Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 21 décembre 1974, Partie 1 samedi 21 (no 51)
[" 4» GAZETTE QUEBEC ssr\u2014' °T OFFICIELLE OFFICIAL DU QUÉBEC GAZETTE PARTIE 1 PART 1 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SI décembre 1974, 106' année, n° 51 9397 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazelle officielle du Québec.2.La Gazelle officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazelle officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et con tient des a vis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Editeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à raidi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher 0398 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December Si, 7974, Vol.106, No.51 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, |)our les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 85 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, S20: du 1er avril au 31 décembre, S15 et du 1er juillet au 31 décembre, 810.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 85 per 100 words.Single copies: 81 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, 815 and from 1 July to 31 December, 810.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972 Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1R 4Y7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1R 4Y7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1974, 106' année, n° 51 9399 AVIS JURIDIQUES\t\tJURIDICAL NOTICES\t\t\t Compagnies \u2014 Loi des\t\tCompanies Act\t\t\t Lettres patentes (1™ partie)\tLetters Patent (Part I)\t\t\t\t Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation :\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating:\t\t\t\t Nom / Name\t\tSiège social / Head Office\tIncorporation Date\t\t AERO-CLIMATISATION CONFORT LTEE.\t\t5635, Charlemagne, Montréal.\t19\t11\t74 1370-4309\t\t\t\t\t AIR CLIMATISE STE-GENEVIEVE INC.et sa version anglaise STE-GENEVIEVE AIR CON DIT IONNING INC.1370-3400\t\t16,587, boulevard Gouin est, Sainte-Geneviève.\t12\t11\t74 LES AMENAGEMENTS DU FIEF INC.\t\t420, boulevard Roche, Vaudreuil.\t28\t10\t74 1359-9428\t\t\t\t\t AMENAGEMENT SARANAC LTEE.and its English version SARANAC DEVELOPMENT LTD.1370-3525\t\t2880, chemin St-Charles, Kirkland.\t12\t11\t74 AMUSEMENTS LABBEE INC.\t\t1105, avenue de Lamontagne est, Val-Bélair.\t15\t11\t74 1359-7919\t\t\t\t\t ANTENNES VIDEO INC.\t\t9, rue de Bretagne, Neufchâtel.\t19\t11\t74 et sa version anglaise VIDEO ANTENNAS INC.1360-3410\t\t\t\t\t LES ATELIERS BEAUCHEMIN INC.\t\t\t06\t11\t74 1360-1315\t\t\t\t\t L'ATELIER DE SERIGRAPHIE DU SAGUENAY INC\t\t197, avenue Riverin, Chicoutimi.\t11\t11\t74 1360-1950\t\t\t\t\t \t\t1200, rue Johnson, Saint-Hyacinthe.\t.02\t12\t74 1360-5407\t\t\t\t\t AUTO J C LAROCHE INC.\t\t341, boulevard Barrette, Joliette.\t.20\t11\t74 1370-4168\t\t\t\t\t AUTOBUS SCOLAIRES N.D.G.INC.\t\tNotre-Dame-de-Grâce.\t19\t11\t71 et sa version anglaise N.D.G.SCHOOL BUS INC.1360-3501\t\t\t\t\t LES AUTOMOBILES APPALACHES LIMITEE\t\t\t.25\t11\t74 1360-3972\t\t\t\t\t AUTOMOBILES LAFITTE INC.\t\t9370, boulevard des Mille-Ile, Saint-François, Laval.\t22\t11\t71 1370-4622\t\t\t\t\t BATTELEC INC.\t\t537, rue Laurier, Saint-Jean.\t28\t10\t74 1359-2233\t\t\t\t\t BOIVIN & COUTURE INC.\t\t1484, Savoie, Orsainville.\t01\t11\t74 1360-0499\t\t\t\t\t GASTON BOIVIN INC .\t\t168, rue Lessard, Loretteville.\t.30\t10\t74 1359-9964\t\t\t\t\t 9400 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December SI, 1974, Vol.106, No.51 Nom / Xame Siège social / Head Office Incorporation Date BOUCHERIE-EPICERIE P.E.LAFOND INC.1370-2261 LA BOUTIQUE RODIER (QUEBEC) INC.1360-0747 BOUTIQUE YO-YO, BAIE COMEAU INC.1360-3667 BRASSERIE LES TROIS BARILS INC.1360-4194 CAMPING POINTE-CALUMET INC .1370-2303 C'A NT R ADEN INC 1360-1448 CAROSSERIE F.G.INC.and its English version F.G.AUTO BODY INC.1359-6051 CENTRE D'ACCUEIL LAHAISE INC.1359-3413 CENTRE DU DISQUE D'ELVIS A MOZART INC.1360-3634 CENTRE INDUSTRIEL DE SEPT-ILES INC.et sa version anglaise SEPT-ILES INDUSTRIAL CENTER INC.1370-3210 CHARAL INC.1370-2923 CHAUSSURES BONNIE & CLYDE INC.et sa version anglaise BONNIE & CLYDE SHOES INC.1360-0325 LES CHAUSSURES LUDOVIC LTEE.et sa version anglaise LUDOVIC SHOES LTD.1359-6978 CHORALIA (QUEBEC) INC.1370-4267 LE CLUB DE GOLF ST-LUC INC.1359-8628 LA COMPAGNIE AGROTHEQUE LIMITEE.1359-7794 COMPAGNIE DE COLLE DE FARINE DOMINION LTEE.et sa version anglaise DOMINION FLOUR PASTE CO.LTD.1370-2634 CONFECTIONS ARBOUR INC.et sa version anglaise ARBOUR CONFECTIONS INC.1370-0927 CONSEILLERS EN ADMINISTRATION D.N.H.INC.et sa version anglaise D.N.H.CONSULTANTS INC.1370-1586 CONSTRUCTION ERGON LTEE.and its English version ERGON CONSTRICTION LTD.1360-4046 495.rue Labelle, Saint-Jérôme.31 10 74 Québec.04 11 74 Baie-Comeau.20 11 74 200, boulevard Lasalle, Baie-Comeau.26 11 74 Pointe-Calumet.31 10 74 615.boulevard Dorchester ouest, 07 11 74 suite 1010, Montréal.9875, rue Clark, Montréal.10 10 74 Saint-Vincent-de-Paul.20 11 74 Baie-Comeau.20 11 74 Montréal.08 11 74 Chemin Hemming, Drummondville.06 11 7-1 315.boulevard Labelle, Rosemère____ 31 10 74 50, chemin St-Charles, BeaconsBeld.15 10 74 3730, boulevard Métropolitain est, suite 410, Montréal.19 11 74 Saint-Luc.22 10 74 20 11 74 Montréal.04 11 74 3150, France-Prime, suite 1-3, Sainte-Foy.200, rue Principale, Sainte-Emélie-de- 21 10 74 l'Energie.903, boulevard Richelieu, Otterburn 25 10 74 Park.Montréal.24 11 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.21 décembre 1374.106' année, n\" 51 9401 Nom / Name CONSTRUCTION ISOREL INC.1370-1990 CONSTRUCTION RODETTE INC.1360-6363 DACTYLOGRAPHIE METROPOLE INC.1370-1487 DEMENAGEMENT J.BRAULT INC.1360-4632 LES DISTRIBUTIONS ARBEC INC.1359-9642 DISTRIBUTION T.M.D.R.INC.1360-3865 DOMAINE DU LAC CACHE INC.1360-2305 EDITIONS BOURGUIGNON INC.1370-1958 ENTREPRENEUR GENERAL G.MANCINI LTEE.et sa version anglaise G.MANCINI GENERAL CONTRACTOR LTD.1370-2121 ENTREPRISES BODOR LTEE.and its English version BODOR ENTERPRISES LTD.1370-1792 LES ENTREPRISES BROOKHAVEN LTEE.and its English version BROOKHAVEN ENTERPRISES LTD.1370-3343 ENTREPRISES CASMAC LTEE.and its English version CASMAC ENTERPRISES LTD.1369-9509 LES ENTREPRISES LESSARD ET LAPLANTE INC____ 1359-8933 LES ENTREPRISES QUEBECOISES DE TRAVAUX EN ELECTRICITE INC.1370-4234 ENTREPRISES SELCORP LTEE.and its English version SELCORP ENTERPRISES LTD.1357-9909 LES ENTREPRISES YVES POUDRIER INC.1370-0869 EPICERIE JACQUES IMBEAU INC.1360-1075 EPICIERS EN GROS UNIVERSEL INC.et sa version anglaise UNIVERSAL WHOLESALE GROCERS INC.1370-4754 ESCOSEPT INC.1369-8477 LES ESTIMATIONS M.L.LTEE.1360-6365 Incorporation Siège social / Head Office Date 9285, rue Chopin, Saint-Léonard.29 10 74 22, de la Fabrique, Cabano.06 12 74 23, rue Roy, Ile-Bizard.24 10 74 123, rue St-Jacques.Saint-Jean.27 11 74 6,700, Me Lynn, Montréal.29 10 74 Bernières.22 11 74 968, 3e Rue, Chibougamau.12 11 74 Montréal.29 10 74 Montréal.30 10 74 1, Place Ville-Marie, suite 1734, 28 10 74 Montréal.237, Brookhaven, Dorval.12 11 74 1, Place Ville-Marie, suite 1734, 07 10 74 Montréal.Montréal.24 10 74 5695, boulevard des Grandes-Prairies, 18 11 74 Saint-Léonard.165, Wellington, Hull.26 08 74 141, Route 201, Hudson.18 10 74 Chicoutimi.05 11 74 195, rue Louvain, Montréal.20 11 74 649 boulevard Laure ouest, Sept-Iles .30 09 74 31, Arthur, Cabano.06 12 74 9402 QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE.December 31, 1974, Vol.108, \\o.51 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date ETRAGEC INC.1360-0564 LES EXCAVATIONS JACQUES CARTIER INC.1359-6713 EXPERTS-CONSEILS MOLAG LTEE.et sa version anglaise MOLAG CONSULTANTS LTD.1370-2063 FERMES D ELEVAGE MICH & KEN INC.and its English version MICH A KEN BREEDING FARMS INC.1369-5176 FIBRE DE VERRE ROUGEMONT INC.1359-32S0 FILTRATION QUEBEC LTEE.et sa version anglaise QUEBEC FILTRATION LTD.1370-4242 FONDATIONS RICHARD LAMER INC.1370-3574 LA FONDERIE CARRIERE INC.et sa version anglaise CARRIBRE FOUNDRY INC.1370-1743 LES FORGES VICTORIA INC.1359-6093 GELEN INC.1370-0489 GESTION E.MATHIEU INC.1370-0158 GESTIONS MERODAL LTEE.and its English version MERODAL HOLDINGS LTD.1360-1984 LE GROUPE FOSBEC INC.1370-2170 LES HABITATIONS DEUX-RIVIERES INC.1360-0986 JAN HOEDEMAN & ASSOCIES INC.1358-9601 HOTEL CYRILLE INC.1370-2097 HOTEL MOTEL CHATEL BOISE INC.1359-4155 IMMEUBLES ALPHONSE DUFOUR INC.1370-0638 LES IMMEUBLES BRUNINI INC.and its English version BRUNINI REALTIES INC.1359-7257 LES IMMEUBLES DENRO LIMITEE.and its English version DENRO PROPERTIES LIMITED 1359-9790 283, boulevard de la Concorde, suite 01 11 74 105, Pont-Viau, Laval.Cap-Santé.15 10 74 Montréal.30 10 74 01314.Charlevoix.Montréal.30 08 74 Saint-Paul-d'Abbotsford 21, Elysée, Place Bonaventure, Montréal.891, rue Abbés-Primeau, Boucher-ville.302, Rang Double, Saint-Urbain.26 is 13 2 S Chester Est.10 166.rue Bellcrive, Roscmère.16 Laval.11 58, Midland, Beaconsfield.11 Montréal .30 Maniwaki.04 1095, des Erables, Québec.29 1063, rue Michel Moreau, Boucherville 30 1997.boulevard Ste-Adèle.Sainte- 27 Adèle.833, boulevard Sacré-Coeur, Saint- 17 Félicien.Montréal.\\Q 09 74 11 74 11 74 10 74 10 74 10 74 10 74 11 74 10 74 11 74 08 74 10 74 09 74 10 74 10 74 620, boulevard Dorchester ouest.Montréal.30 10 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1974.106' année, n° 51 9403 Nom / Vainc Siège social / Head Office Incorporation Date LES IMMEUBLES J.-C.MILOT INC.1370-3616 LES IMMEUBLES ROGER GAREAU INC.1360-0341 IMPRIMERIE VIC INC.1359-9279 INDUSTRIES N.R.C.INC.et sa version anglaise N.R.C.INDUSTRIES INC.1357-4579 INGECAN QUEBEC LIMITEE.et sa version anglaise INGECAN QUEBEC LIMITED 1370-4036 LES ISOLATIONS D'OR LTEE.and its English version GOLD INSULATIONS LTD.1370-2295 LES JEUX D'ORDINATEURS VIDEO VEND INC.and its English version VIDEO VEND COMPUTER GAMES INC.1370-3319 LABORATOIRE DOCEL INC.1370-0828 JEAN-GUY LAPOINTE INC.1360-0333 M.LATENDRESSE & FILS INC.1360-1109 P.H.LEVESQUE LTEE.1360-2057 LINGERIE HELENE-FRANCE INC.1370-4176 MAISONS DE L'AVENIR N.R.LTEE.1360-0432 LA MAISON DU STEAK MARCONI LTEE et sa version anglaise MARCONI STEAK HOUSE LTD.1360-1026 MARCHANDISES SECHES ATLAS LTEE.and its English version ATLAS DRY GOODS LTD.1360-0572 JEAN MASSON INC.1358-5914 METALLURGIE B.B.L.INC.1359-7539 MEUBLES DESGRANGES INC.1359-9469 LES MODES D'UN SEUL REGARD INC.and its English version JUST LOOKING FASHIONS INC.1370-2527 630, boulevard St-Joseph, Drummondville.Val-d'Or.Victoriaville.Sainte-Madeleine 4130, Tour de la Bourse, Place Victoria Montréal.378, avenue Beaumont, Montréal 1, Place Ville-Marie, suite 3235.Montréal.875, rue Boissy, Saint-Lambert.Saint-Rémi.892, rue de l'Eglise, Sainte-Béatrix____ 198.rue St-Cyrille, Normandin.26, Place Bourget-Nord, Joliette.Lévis.259, rue Jean-Talon ouest, Montréal.12 11 74 31 10 74 13 11 7 4 26 06 74 18 11 74 31 10 74 11 11 74 18 10 74 31 10 74 05 11 74 11 11 74 18 11 74 04 11 74 16 08 74 2075, boulevard St-Laurent, Montréal 01 11 74 498, Julien, Cap-de-la-Madeleine.17 10 74 1365, rue Chanoine-Morel, Sillery .18 10 74 413, Rang Haut St-Pierre, Saint- 28 10 74 Zéphirin 5800, Cavendish, Cavendish Mail, 01 11 74 Côte-Saint-Luc. 9404 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December SI, 1974, Vol.100, Ko.51 Nom / Name MONDE DE VIBRATIONS SONORES J.INC.et sa version anglaise J.VIBRATION SOUNDS WORLD INC.1370-2931 MOTEL CADILLAC LTEE.1370-2790 MOTEL MARTINBEAU, INC.1359-6580 OUTILLAGE JES INC.and its English version JES TOOLING INC.1370-1693 PADAS INC.1359-3249 PATISSERIE ET CHARCUTERIE BOURRET INC.and its English version BOURRET DELICATESSEN AND PASTRY INC.1359-5368 PAVILLON DES CEDRES CHUTE-AUX-OUTARDES INC.1360-3675 PIECES D'AUTO BOIS-FRANCS INC.et sa version anglaise BOIS-FRANCS AUTO PARTS INC.1360-1141 LES PLACEMENTS BAXAN LTEE.et sa version anglaise BAXAN INVESTMENTS LTD.1357-9149 LES PLACEMENTS CALABRESE & ROVETO LTEE.and its English version CALABRESE .Initial, 1972 Bassin.1974 Montreal.Initial, 1961 à/to 1974 incl.Sainte-Foy.Initial, 1974 Saint-Laurent.Initial, 1974 Dolbeau.Initial, 1965 à/to 1974 incl.Dolbeau.Initial, 1960 à/to 1974 incl.' GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1974, 106' année, n' 51 9417 Nom de la compagnie Name of the company CLUB CLEMENCE INC.125305 CLUB DU LAC CHOCHET INC.236661 CLUB DE LA PEU DR IX GRISE INC.236347 CLUB DE LA RIVIERE L'ORIGNAL INC.126604 CLUB ST-ALEXANDRE.236386 CLUB SAVARI INC.236396 LA COLONIE DE VACANCES NOTRE-DAME DE MONTMORENCY LAVAL 93574 LE COMITE FEDERATIF DE PROMOTION TOURISTIQUE ET COMMERCIALE DE PORT-JOLI INC.134311 LA COMPAGNIE MINIERE DE LA VALLEE DU SAINT-MAURICE 153748 CONSEIL DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DU CENTRE DU QUEBEC INC.97661 CONSEIL ECONOMIQUE REGIONAL DE LA MAURICIE INC.98149 CONSTRUCTION TERPLACE INC.81402 LA CORPORATION DU CENTRE D'ACCUEIL DE MONT-LOUIS 112743 CROYDON AUTO PARTS INCORPORATED.53982 ENREGISTREUSES AUTOMATIQUES DE QUEBEC INC.107089 LES ENTREPRISES VERDI INC.114655 EXPLORATION LAC BRISEBOIS LTEE.102524 LE FAUBOURG DE LA PAIX.132600 FENDERSON SAYABEC INC.42225 LA FERME STE-LOUISE LTEE.67375 LES GALERIES DRUMMOND INC.130445 HARBOUR TERMINALS REALTIES INCORPORATED.1727-1913 HURON FOOTWEAR INC.232267 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Forestville.Initial, 1962 à/to 1965 incl.1974 St-Siméon.Initial, 1960 à/to 1974 incl.Ste-Thérèse-de-Colombier Initial, 1959 à/to 1974 incl.Saint-Jérôme.Initial, 1962 à/to 1969 incl., 1974 St-Alexandre.Initial, 1948 à/to 1974 incl.Alma.Initial, 1962 à/to 1974 incl.Québec.Initial, 1966 à/to 1968 incl., 1974 Saint-Jean-Port-Joli.Initial.1972 à/to 1974 incl.Grand'Mère.Initial.1932 à/to 1974 incl.Victoriaville .1974 T rois-Rivières.1974 Montréal.Initial, 1972, 1974 Saint-Maxime-du-Mont- Initial, 1971 à/to Louis.1974 incl.Croydon.1961.1962.1964 à/to 1974 incl.Sainte-Foy .1970 i/lo 1974 incl.Montréal-Nord.1974 Québec.Initial, 1968 à/to 1974 incl.Québec.____ Initial, 1974 Sayabec.1968,1971.1974 Ste-Béatrix.Initial, 1962.1964, 1965, 1971 à/to 1974 incl.Montréal.Initial.1974 Montreal.Initial, 1932 à/to 1974 incl.Loretteville.1968 à/to 1974 incl. 94 IS QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December St, 1974, Vol.106.No.61 Nom de la compagnie Nome of the company LES IMMEUBLES TRANS-CANADA CIE LTEE.32070 INVESTISSEMENTS ROTAN INC.146774 DANIEL JUTRAS INC.135395 LAKE GEORGE DEVELOPMENT INC.78410 VIATEUR LANGL01S LTEE.232648 LA LIGUE DU SACRE COEUR DE ST-EDOUARD DE PORT ALFRED SOCIETAIRES DU TRENTAIN INC.16728 RODOLPHE LORANGER INC.234786 MAJORETTES STE-TRINITE DE CONTRECOEUR.98829 MAY LAKE CLUB.236410 METECH INC.139307 MOTEL GAUTHIER INC.101124 MOUNT-ROYAL HOLDING COMPANY INC.90612 PALAIS DU COMMERCE INCORPORE.21058 EUGENE PARENT & FILS LTEE .130794 PERICO LTEE.138526 PONT VIAU CAR WASH INC.64464 GERARD POULIN (1961) INC.63417 RAYMAC MINING LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) .113620 RESEARCH INSTRUMENTATION LTD.39216 RESTAURANT CHEZ BORIS INC.147467 RICHER TRANSPORT LTEE.53917 ROCKE-WILLIAM CIE LTEE.1110-5681 ROTAN INVESTMENTS INC.146774 .NELSON SAB INC.130959 SERGAD INC.95436 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1974 Dorval.Initial.1974 Laval.1972 et/and 1974 Montréal.Initial, 1964, 1965, 1967 à/to 1974 incl.Bic.1968 à/to 1974 incl.Port-Alfred.1946, 1965 à/to 1967 incl.1974 Trois-Rivières.1956 à/to 1974 incl.Contrecoeur.Initial, 1971 à/to 1974 incl.Montcerf.Initial, 1966 à/to 1974 incl.Montréal.Initial, 1972 à/to 1974 incl.Tracy.Initial, 1968 à/to 1974 incl.Montreal.Initial, 1966 à/to 1974 incl.Montréal.1974 Beauport., Initial.1974 Montréal.Initial, 1974 Montreal.1963 à/to 1974 incl.Québec.1974 Montreal.1970 à/to 1974 incl.Montreal.1961 à/to 1974 incl.Joliette.Initial, 1974 Mont-Rolland.Initial, 1960 à/to 1974 incl.Montréal.Initial.1969 à/to 1974 incl.Dorval.Initial, 1974 Thetford Mines.Initial, 1974 LaSalle.1974 GAZETTK OFFICIELLE DC QUÉBEC.21 décembre 1974.106' aimée.n° 51 9419 Nom de la compagnie Ifamt of Ihe company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed SHOW-MART INCORPORATED .21058 SOCIETE DE GESTION MONT-ROYAL INC.90612 SUPREM, INC.1158-5247 TAPATCO INDUSTRIES LTD.117589 BENOIT THIBAULT AUTOMOBILE LTEE- 56407 TRANSPORT LAVOIE (1973) LTEE.142571 TREMBLAY LUMBER CO.LTD.6572 TRANS-CANADA REALTIES CO.LTD.32670 Montreal.1974 Montréal.Initial, 1966 à/to 1974 incl.Ste-Foy.1974 Ayer's Cliff.1974 St-Coeur-de-Marie.Initial.1961 à'to 1974 incl.Montmorency.Initial, 1974 Québec.1955 à/to 1974 incl.Montreal.1974 59375-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59375-0 Pierre Desjardins.Director of the Companies Service.Révocation de dissolution Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, en vertu du paragraphe a de l'article 5/ de la Loi des renseignements sur les compagnies, qu'il a jugé à propos de faire droit à la demande d'intéressés faite dans les délais légaux à l'effet de révoquer la dissolution de Revocation of dissolution The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice, that pursuant to paragraph a of section 5/ of the Companies Information Act, he deemed it advisable to grant the petition of the interested parties made within the legal time limit, praying to revoke the dissolution of Nom des compagnies\tDissolution\tGazette officielle No Name of the companies\tDate\tOfficial Gazette No.FONDS ADANAC INC.\t.07 12 74\t49 ADANAC FUNDS INC.\t\t ODIN HOLDINGS COMPANY LIMITED.\t.02 03 74\t9 en vertu de ladite loi et qu'il révoque la dissolution desdites compagnies.En conséquence, lesdites compagnies sont censées n'avoir jamais été dissoutes en vertu de ladite loi.sans préjudice aux droits acquis par toute personne entre la dissolution et la révocation.Le directeur du service des compagnies, 59375-0 Pierre Desjardins.pursuant to the said Act and that he revokes the dissolution of the said companies.Consequently, the said companies are considered as having never been dissolved under the said Act, without prejudice to the rights acquired by any person between the dissolution and the revocation.Pierre Desjardins.59375-0 Director of the Companies Service.Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Change of name \u2014 Act Applications Serge Bilodeau Prenez avis que M.Serge Bilodeau, domicilié et résidant au 14, Du Couvent, Bienville, Québec, présentera une demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour que son nom de famille soit changé pour le nom de Côté.Le procureur du requérant, 59364-50-2-o Raynald Ti\"r«:eox, acucal.Serge Bilodeau Notice is given that Mr.Serge Bilodeau, domiciled and residing at 14 Du Couvent, Bienville, Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his family name to that of Coté.Raynald Tiroeon, lawyer, 59364-50-2 Attorney for the applicant. 9420 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.December 21, 1974, Vol.106, No.51 N'ila .Margaret Graham Bloomfield Prenez avis que Xila Margaret Graham Bloomfield, domiciliée et résidant au 12768.Ethier Circle, Pierre-fonds, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Lila Margaret Graham Bloomfield.Granby, ce 1er novembre 1974.Les procureurs de la requérante, 59305-50-2-o Ahsenault & Lagacé.Jean Laurier Avis est par les présentes donné que Jean Laurier, présentement domicilié au 158, rue Champlain, Hull, province de Québec, entend présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Jean Laurier Provost.Hull, le 25 novembre 1974.Le procureur du requérant.59306-50-2-o Me Daniel Gervais.Léon Simon Souillac Avis est par les présentes donné que Léon Simon Souillac, connu sous le nom de Léon Baldwin, présente une requête au ministre de la justice du Québec demandant de changer son nom en celui de Léon Simon Baldwin.Si cette requête était accordée, le nom et l'adresse de chaque personne vivante dont le nom sera changé sont les suivants: Léon Simon Souillac, 4000 de Maisonneuve, app.810, Montréal,Que., et son épouse: May Souillac (née Brownrigg).HôpitalS aint-Michel-Ai change, Mastaï.Québec 5.Montréal, le 2 décembre 1974.Les procureurs du requérant, 59332-50-2-o Poiliot.Dion & Guilbavlt.Paul Hum Avis est donné que Paul Hum, des cité et district de Montréal, s'adressera au ministre de la justice du Québec pour obtenir l'autorisation de changer son nom en celui de Paul Hombert, en vertu de la Loi du changement de nom.Le procureur du requérant.59374-50-2-o Ciiari.es Coderre, c.r., avocat.Joseph Archille Cook Avis est par les présentes donné que Joseph Archille Cook, présentement sans emploi, domicilié et résidant au 6693, rue St-Denis, appartement 1.à Montréal, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Roger Cook.Montréal, 24 octobre 1974.Le procureur du requérant.59333-50-2-o Me Pailf.Lafontaine.Nila Margaret Graham Bloomfield Notice is given that Nila Margaret Graham Bloomfield, domiciled and residing at 12768 Ethier Circle, Pierrefonds, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing her name to Lila Margaret Graham Bloomfield.Granby, November 1, 1974.Arsenavlt & Lagacé, 59305-50-2 Attorneys for the applicant.Jean Laurier Notice is hereby given that Jean Laurier, presently domiciled at 158 Champlain Street, in Hull, Province of Québec, intends to present a petition to the Lieutenant-Governor in Council in order to obtain a decree permitting him to change his name to Jean Laurier Provost.Hull, November 25, 1974.Me Daniel Gervais, 59306-50-2-o Attorney for the petitioner.Léon Simon Souillac Notice is hereby that Léon Simon Souillac, known under the name of Léon Baldwin, will present a petition to the Minister of Justice of Québec to change his name in that of Léon Simon Baldwin.Should the petition be granted, the name and the address of each living person whose name will be changed are the following: Léon Simon Souillac, 4000 De Maisonneuve.apt.810, Montreal.Que.and his wife: May Souillac (née Brownrigg), Hôpital Saint-Michel-Archange, Mastaï, Québec 5.Montreal, December 2, 1974.Pouliot, Dion & Guilbault, 59332-50-2-o Attorneys for the petitioner.Paul Hum Notice is given that Paul Hum.of the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Justice of Québec in order to obtain authorization to change his name to that of Paul Hombeit, pursuant to the Change of Name Act.Chaules Codehre, q.c, lawyer.59374-50-2-o Attorney for applicant.Joseph Archille Cook Notice is hereby given that Joseph Archille Cook, presently unemployed, domiciled and residing at 6693 Saint-Denis Street, Apartment 1.in Montreal, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec, for an order changing his name to Roger Cook.Montreal, October 24, 1974.Me Paule Lafontaine.59333-50-2 Attorney for the applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1974.106' année, n° 51 9421 Aline Courtenianche Avis est donné que Aline Courtemanthe.domiciliée et résidant chemin Bromont, à Waterloo, district de Bedford, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Bernadette Aline Courtemanche.Les procureurs de la requérante, 59391-51-2-0 Arsenault & Laoacé.Avis divers CONSKH.REGIONAL DE PASTORALE DE LIMOILOU Avis est donné qu'en veitu de la Loi des évéques catholiques romains, statuts refondus, 1964, chapitre 304, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur des lettres patentes en date du 22 octobre 1974, constituant en corporation « CONSEIL REGIONAL DE PASTORALE DE LI.MOILOU >.Le siège social de la corporation est situé à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.59375-0 LPE: 1359-8545 CONSEIL REGIONAL DE PASTORALE DE LORETTE Avis est donné qu'en vertu de la Loi des évéques catholiques romains, statuts refendus, 1964, chapitre 304, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur des lettres patentes en date du 22 octobre 1974, constituant en corporation « CONSEIL REGIONAL DE PASTORALE DE LORETTE ».Le siège social de la corporation est situé à Lorette-ville, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.59375-0 LPE: 1359-8487 CONSEIL REGIONAL DE PASTORALE DE LOTBINIERE ET DES BOIS-FRANCS Avis est donné qu'en vertu de la Loi des évéques catholiques romains, statuts refondus, 1964, chapitre 304, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur des lettres patentes en date du 22 octobre 1974, constituant en corporation « CONSEIL REGIONAL DE PASTORALE DE LOTBINIERE ET DES BOIS-FRANCS ».Le siège social de la corporation est situé à Laurier Station, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.59375-u LPE: 1359-8495 Aline Courtemanche Notice is given that Aline Courtemanche, domiciled and residing on Biomont Road, in Waterloo, District of Bedford, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing her name to Bernadette Aline Courtemanche.Arsenault & La Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155, boulevard Je-Me-Souviens, à Laval, P.Q., le VINGT ET UNIÈME jour de JANVIER 1975, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du shérif.Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 10 décembre 1974.59408-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal (TA CAISSE POPULAIRE No.05-012074-74X *-> DESJARDINS DES EM- l PLOYES MUNICIPAUX DE MONTREAL, a body polilic having its principal place of business at 305 Craig Street East, Montreal, plaintiff; vs LOUIS-MARIE PAUL, gentleman, domiciled at 93 Labrie Street, Laval-des-Rapides, District of Montreal, defendant.\"An emplacement fronting on Labrie Street, in the Municipality of Laval-des-Rapides, City of Laval, such emplacement being known and described as lots numbers seventy-nine and eighty of the resubdivision of lot number five of the official subdivision of original lot number two hundred forty-two on the official cadastre for the Parish of Saint-Martin, said lot (242-5-79) measuring sixty feet in width, and said lot (242-5-80) measuring forty-five feet in width by seventy-three feet in depth, English measure and more or less, as well as the buildings bearing civic number 93 Labrie Street and all other buildings being erected on this piece of land.This immoveable is a one-family dwelling, not subject to any lease.\" To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je-Me-Souviens Boulevard, in Laval, P.Q.on the TWENTY-FIRST day of JANUARY, 1975, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, December 10, 1974.59408 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( T A CIE H.F ORTIE R Cour Provinciale, ) LTEE, corps politique No 200-02-002735-746.) légalement constitué ayant sa \\ place d'affaires au 2680, rue Dalton, Parc Colbert, Ste-Foy, district de Québec, m JEAN-MARIE BÉDARD, commerçant, faisant affaires au 173, St-Ambroise, Québec, district de Québec sous la raison sociale de « Buffet St-Ambroise ».« Un immeuble connu et désigné comme étant la redivision trois de la subdivision quatre-vingt-quatorze, du lot originaire numéro trois (lot 3-94-3) du cadastre officiel pour la paroisse de Notre-Dame-des-Anges, division d'enregistrement de Québec, avec bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances.* Pour être vendu au bureau du shérif.Palais de Justice, 12, rue St-Louis, Québec, le TRENTIÈME jour de JANVIER 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 16 décembre 1974.59417-0 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit: (TA CLE H.FORT1ER Provincial Court, ) LTEE, a body politic No.200-02-002735-746.1 legally incorporated having ' its place of business at 2680 Dalton Street, Pare Colbert, Ste-Foy, District of Québec, vs JEAN-MARIE BÉDARD, merchant, carrying on business at 173 Saint-Ambroise, Québec, District of Québec, under the trade name of \"Buffet St-Ambroisc\".\"An immoveable known and described as being redivision three of subdivision ninety-four of original lot number three (lot 3-94-3) on the official cadastre for the Parish of Notre-Dame-des-Anges, Québec Registration Division, with the building erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the Court House.12 Saint-Louis Street.Québec, on the THIRTIETH day of JANUARY, 1975, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, December 16, 1974.59417 9544 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 21, 1974, Vol.lOn, No.51 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir:/\" Tv^'AURICE DROUYN, _ a ^en-Cour Provinciale.) teur-géomètie, domicilié et No 105-882.) résidant à 6031, boulevard Henri-\\ liourassa, Charlesbourg, Québec 7, vs J.P.MARTINEAU.4500, boulevard Henri-Bou-rassa, Québec 7 et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Québec, mis en cause.« Un emplacement connu et désigné comme étant le lot numéro seize (16), subdivision du lot originaire numéro mille soixante-quatorze (lot 1074-16) du cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg, avec maison dessus érigée, portant le numéro civique 6405, Place Bonaparte, circonstances et dépendances.Ledit lot est borné vers le nord-est par les numéros 295-5 et 296-5 (Avenue Edouard), vers le sud-est par le lot numéro 1074-17, vers le sud-ouest par le lot numéro 1074-15 et vers le nord-ouest par le numéro 1074-3 (Place Bonaparte), mesurant cent pieds (100') de largeur, sur une profondeur de cent f ieds (100').Contenant en superficie neuf mille neuf cent quatorze pieds carrés, mesure anglaise (9,914).Ce lot comporte une courbe de raccordement de vingt pieds (20') de rayon à son coin angulaire nord-est.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec.116, rue St-Pierre, Québec, le TRENTIÈME jour de JANVIER 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 16 décembre 1974.59419-c.Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: / Xyf ARIE PAULE D'AMOURS, Cour Supérieure,) AVA domiciliée et résidant au No 11-317.) 968, Duehesneau, Québec, distiict l de Québec vs CLAUDE GAUVIN, paysagiste, domicilié et résidant au 2390, rue Notre-Dame, Notre-Dame-des-Laurentides, distiict de Québec.Une certaine étendue de terrain connue et désignée comme étant une partie non subdivisée du lot cinq cent vingt-quatre (524 ptie n.s.) du cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg, division d'enregistrement de Québec, mesurant deux cent cinquante-trois pieds et cinq dixièmes (253.5') au sud, deux cents pieds (200') à l'est, cent quarante-sept pieds (147') dans la partie joignant la propriété de M.Jos Mac Dermott ou représentants et cent vingt-neuf pieds et trois dixièmes (129.3') le long du lot 525, au nord et cent pieds (100') le long de la rue Notre-Dame et soixante-dix pieds (70') le long de la propriété de M.Jos Mac Dermott ou représentants à l'ouest, le tout plus ou moins et mesure anglaise.Cette partie non subdivisée du lot 524 est bornée à l'est par la route 54 actuelle, au sud par une partie du lot 524 appartenant à M.Raymond Bédard ou représentants, à l'ouest partie par la rue Notre-Dame et partie par une partie du lot 524, appartenant à M.Jos Mac Dermott ou représentants, au nord partie par une partie du lot 524 appartenant à Jos Mac Dermott ou Fieri Facias de Terris Québec, to wit: l TOTAURICE DROUYN, land-Provincial Court,) -Ivlsurveyor, domiciled and re- No.105-882.) siding at 6031 Henri Bourassa l Boulevard, Charlesbourg, Québec 7, vs J.P.MARTINEAU.4500 Henri-Bourassa Boulevard, Québec 7, and THE REGISTRAR for the Québec Registration Division, mis en cause.\"An emplacement known and described as being lot number sixteen (16), subdivision of original lot number one thousand seventy-four (lot 1074-16) on the official cadastre for the Parish of Charlesbourg, with the house erected thereon, bearing civic number 6405 Place Bonaparte, appurtenances and dependencies.The said lot is bounded towards the northeast by numbers 295-5 and 296-5 (Edouard Avenue), towards the southeast by lot number 1074-17, towards the southwest by lot number 1074-15 and towards the northwest by number 1074-3 (Place Bonaparte), measuring one hundred feet (100') in width, by a depth of one hundred feet (100').Covering a surface area of nine thousand nine hundred fourteen square feet, English measure (9,914).There is an easement curve having a radius of twenty feet (20') at the northeast corner of said lot.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St-Pierre Street, Québec, on the THIRTIETH day of JANUARY, 1975, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, December 16, 1974.59419 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: ( -KiT ARIE PAULE D'AMOURS, Superior Court.) AVA domiciled and residing at 968 No.11-317.) Duehesneau, Québec City, District of ( Québec, m CLAUDE GAUVIN, landscaper, domiciled and residing at 2390 Notre-Dame Street, Notre-Dame-des-Laurentides, District of Québec.A certain piece of land known and described as being a non subdivided part of lot five hundred twenty-four (524 N.S.Pt.) on the official cadastre for the Parish of Charlesbourg, Québec Registration Division, measuring two hundred fifty-three and five tenths feet (253.5') on the south, two hundred feet (200') on the east, one hundred forty-seven feet (147') for that part adjoining the property of Mr.Jos MacDermott or representatives and one hundred twenty-nine and three tenths feet (129.3') along lot 525, on the north and one hundred feet (100') along Notre-Dame Street and seventy feet (70') along the property of Mr.Jos MacDermott or representatives on the west, the whole in English measure, and more or less.Said non subdivised part of lot 524 is bounded on the east by the present Highway 54, cn the south by a part of lot 524 belonging to Mr.Raymond Bédard or representatives, on the west partly by Notre-Dame Street and partly by a part of lot 524 belonging to Mr.Jos MacDermott or representatives, on the north partly by a part of lot 524 belonging to GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1974, 106' année, n° SI 9545 représentants et partie par une partie du lot 525 appartenant à M.I.aperrière ou représentants.Tel que le tout est actuellement avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances et portant le numéro civique 2390.Ave.Notre-Dame, Notre-Dame-des-Laurentides, et sujet ledit immeuble à une servitude de passage en faveur de l'Hydro-Québec relativement à une ligne de transmission et à un autre droit de passage donnant accès à la partie du lot 524 appartenant à Jos Mac Dermott ou représentants.L'immeuble vendu l'est avec droit de passage pour pomper l'eau de la rivière sur une partie du lot 524 appartenant à Raymond Bédard.Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec.116, rue St-Pierre, Québec, le VINGT-NEUVIÈ-MK jour de JANVIER 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 16 décembre 1974.59418-0 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: (T A VILLE DE QUÉBEC, cor-Cour Municipale.) poration légalement consti-No 119 de 1973 \\ tuée, ayant son siège social dans les \\ ville et district de Québec, vs J.ALBERT VOYER.domicilié et résidant à 76 ouest, des Bouleaux, en les ville et district de Québec.« La resubdivision A de la subdivision trois cent soixante et un du lot originaire quatre cent vingt-huit (428-61-A) du cadastre officiel de la paroisse de St-Roch Nord, dans la ville de Québec, de figure rectangulaire, bornée au nord-est par le lot 428-360-B, au sud-est par le lot 429-40 (Ave des Bouleaux), au sud-ouest par le lot 428-361-B et au nord-ouest par le lot 428-352 (ruelle).Mesurant quinze pieds (15') de largeur sur soixante-quinze pieds (75') de profondeur.Contenant en superficie mille cent vingt-cinq pieds carrés (1,125 p.c.) mesures anglaises.Le tout, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» « Ainsi que la resubdivision B de la subdivision trois cent soixante et un du lot originaire quatre cent vingt-huit (428-361-B) du cadastre officiel de la paroisse de St-Roch Nord, dans la ville de Québec, de figure rectangulaire, bornée au nord-est par le lot 428-361-A, au sud-est par le lot 429-40 (Ave des Bouleaux), au sud-ouest par le lot 428-361-B et au nord-ouest par le lot 428-352 (ruelle).Mesurant quinze pieds (15') de largeur sur soixante-quinze pieds (75') de profondeur.Contenant en superficie mille cent vingt-cinq pieds carrés (1,125 p.c), mesures anglaises.Le tout, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» « Ainsi que la resubdivision A de la subdivision trois cent soixante-deux du lot originaire quatre cent vingt-huit (428-362-A) du cadastre officiel de la paroisse de St-Roch Nord, dans la ville de Québec, de figure rectangulaire, bornée vers le nord-est par le lot 428-361-B, vers le sud-est par le lot 429-40 (Ave des Bouleaux), Jos MacDermott or representatives and partly by a part of lot 525 belonging to Mr.Laperrière or representatives.As the whole presently subsists with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, said building bearing civic number 2390 Notre-Dame Avenue, Notre-Dame-des-Laurcntides; the said immoveable is subject to a right of way in favour of HydroQuébec, for a power line, and to another right of way providing access to that part of lot 524 belonging to Jos MacDermott or representatives.The immoveable is sold with the right to pump water from the river over a part of lot 524 belonging to Raymond Bédard.To be sold at the Québec Registry Office.116 Saint-Pierre Street.Québec City, on the TWENTY-NINTH day of JANUARY, 1975, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec.December 16, 1974 .59418 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: ( ENÊ LAMPRON, secu-No.500-02-007568-749X rity agent, residing at I 29 Rielle Street, in Verdun, District of Montreal, plaintiff, h RENÉ PRUD'HOMME, residing at 10 Lafleur Street, in Verdun, District of Montreal, defendant.The immoveable hereinafter described, property of the defendant, namely: \"An emplacement located in Pointe-Calumet, known and described as being lots numbers ninety-nine and one hundred (99 and 100) of the subdivision of original lot number one hundred seven (107) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Saint-Joseph-du-Lac, with a building erected thereon bearing civic number 282 on 29th Avenue in Pointe-Calumet\" To be sold at the County of Two Mountains Registry Office, located at 140 Saint-Eustache Street (Place dii Chêne).Saint-Eustache, on MONDAY, the TWENTY-SEVENTH day of JANUARY, 1975, at TWO o'clock in the afternoon.GaBRIELLE Fol'RNELLE, 59411 Assistant Sheriff.Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Terrebonne ( pUY DESMARAIS, No.700-05-000,109-748.< ^ plaintiff, vs MARCEL * LAURENDEAU.residing and domiciled at 4765 Lévesque Boulevard, Apt.15, Chomedey, defendant.The immoveable hereinafter described, to wit: \"Three lots of land known and described on the official plan and in the book of reference for the Parish of Saint-Placide as forming part of lot number ninety-seven (Pt.97); each one of the said lots measuring fifty feet (50') in width by one hundred eighty feet (180') in depth, English measure and bounded as follows: in front by the Ottawa River, in rear, on the remaining part of the said lot niuety-seven (97) by the property of Placide Carrière or representatives and on both sides by a part of the said lot number ninety-seven (Ft.97) belonging to B.Goossen or representatives and on the other side by a part of the said lot number ninety-seven (Pt.97) belonging to J.-E.Ouellette or representatives; with a right of way along the line of the property of Hermas Brisebois on lot ninety-eight (98) of said cadastre, to circulate from the public road to the land presently mortgaged.To be withdrawn however, a part of the said lot number ninety-seven (Pt.97) according to a deed of sale executed before Me Claude Seguin, notary, dated the fifteenth of September one thousand nine hundred sixty-nine (1969) and registered in Two Mountains under number 135859. 9548 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, December 21, 1974, Vol.106, No.51 Avec la maison y érigée (il y a le numéro civique 3289) sur la route 29, St-Placihe, comté de Deux-Montagnes.Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Deux-Montagnes, situé 140, rue Saint-Eustache (Place Du Chêne), Saint-Eustache, province de Québec, MERCREDI, le VINGT-DEUXIÈME jour de JANVIER 1975, à QUATORZE heures.Le shérif adjoint.Bureau du shérif, Gabrielle Fournelle.Ce 5 décembre 1974.59397-o With the house erected thereon (bearing civic number 3289) on Highway 29, in Saint-Placide, County of Two Mountains.As the whole now subsists with all active and passive, apparent or non apparent servitudes attaching to said immoveable.\" To be sold at the County of Two Mountains Registry Office, located at 140 Saint-Eustache Street (Place du Chêne), Saint-Eustache, Province of Québec, on WEDNESDAY, the TWENTY-SECOND day of JANUARY, 1975, at TWO o'clock in the afternoon.Gabrielle Fournelle, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.December 5, 1974 .59397 Canada \u2014 Province de Québec Cour provinciale \u2014 District de Terrebonne C TJTERVÉ ROBERT, demeu-No 700-02-0300-740.< * A rant et domicilié au 14, ' avenue Robert, Ste-Thérèse, district de Terrebonne, demandeur, rs EUCLIDE LAVERGNE, demeurant et domicilié au 86, avenue des Mille-Iles à Ste-Thérèse-Ouest, district de Terre-bonne, défendeur, et LE REGISTRATEUR du bureau d'enregistrement du comté de Terrebonne, mis en cause.L'immeuble ci après décrit en la possession du défendeur: « Un emplacement situé en la municipalité de Ste-Thérèse-Ouest, connu et désigné comme étant le lot numéro cent un de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent vingt-quatre (124-101) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Thérèse-de-Blain ville.Mesurant dans sa ligne nord-ouest quatre-vingt-quatorze pieds et huit dixièmes de pied (94.8'); dans sa ligne sud-est quatre-vingt-quatorze pieds et neuf dixièmes de pieu (94.9') ; dans ses lignes sud-ouest et nord-est, cinquante pieds (50') chacune.Contenant en superficie quarante-sept mille quatre cent vingt-cinq pieds carrés (47,425 pi.ca.) mesure anglaise et plus ou moins.Avec bâtisse dessus construite portant le numéro civique 86, avenue des Mille-Iles dans ladite municipalité.Ainsi que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit immeuble et notamment avec droit en commun avec les autres y ayant droit sur une plage établie pour le bénéfice de tous les propriétaires de loLs subdivisés par le vendeur.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Terrebonne situé Chambre 106, Palais de Justice, 400, rue Laviolette St-Jérôme, JEUDI le VINGT-TROISIÈME jour de JANVIER 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du shérif, Gabrielle Fournelle.St-Jérôme, le 6 décembre 1974 .59412-0 Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Terrebonne C TLTERVÉ ROBERT, resi-No.700-02-0300-740.< 11 ding and domiciled at I 14 Robert Avenue, Sainte-Thérèse, District of Terrebonne, plaintiff, es EUCLIDE LAVERGNE, residing and domiciled at 86 Des Mille-Iles Avenue, in Sainte-Thérèse-West, District of Terrebonne, defendant, and THE REGISTRAR for the County of Terrebonne Registry Office, mis en cause The immoveable hereinafter described, property of the defendant: \"An emplacement located in the Municipality of Sainte-Thérèse-West, known and described as being lot number one hundred and one of the official subdivision of original lot number one hundred twenty-four (124-101) on the official plan and in the book ot reference for the Parish of Sainte-Thérèse-de-Blainville.Measuring on its northwest line ninety-four and eight tenths feet (94.8') ; on its southeast line ninety-four and nine tenths feet (94.9') ; on its southwest and northeast lines fifty feet (50') each.Covering an area of forty-seven thousand four hundred twenty-five square feet (47,425 sq.ft.), English measure and more or less.With a building erected thereon bearing civic number 86 Des Mille-Iles Avenue, in the said Municipality.As the whole now subsists with all active and passive, apparent or nonapparent servitudes attaching to said immoveable, namely the right of access to a beach, in common with others entitled thereto, established for the benefit of all owners of lots subdivided by the vendor.\" To be sold at the County of Terrebonne Registry Office, located in the Court House, 400 Laviolette Street, Room 106, Saint-Jérôme, on THURSDAY, the TWENTY-THIRD day of JANUARY, 1975, at TEN o'clock in the forenoon.Gabrielle Fournelle, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Saint-Jérôme, December 6, 1974.59412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1974, 10G< année, ti° 51 9549 TROIS-RIVIÈRES TROIS-RIVIÈRES Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Trois-Rivières (TE PROCUREUR GÉNÉRAL DE No 35-579.-} *-> LA PROVINCE DE QUÉBEC, ' représentant sa Majesté du Chef de la province de Québec, demanderesse, vs PIERRE ALBERT DUMONT, registrateur, résidant à ville de Bécancour.district de Trois-Rivières, défendeur.< Lots No 190 et 191 étant partie du cadastre de Bécancour, avec maison dessus construite, portant le numéro civique 2245, avenue Nicolas-Perrot.à Bécancour, district de Trois-Rivières.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Bécancour, division No 1, 3050, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour.MERCREDI, le DIX-NEUVIÈME jour du mois de FEVRIER, 1975, à TROIS heures de l'après-midi.Le shérif adjoint.Bureau du shérif, Fernande Turgeon.Trois-Rivières, le 9 décembre 1974.59398-0 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Trois-Rivières THE ATTORNEY GENERAL OF THE PROVINCE OF QUÉBEC, representing Her Majesty in right of the Province of Quebec, plaintiff, vs PIERRE ALBERT DUMONT, Registrar residing in the Town of Bécancour, District of Trois-Rivières.defendant.\"Lots Nos.190 and 191 forming part of the cadastre of Bécancour, with the house erected thereon, bearing civic number 2245 Nicolas-Perrot Avenue, in Bécancour, District of Trois-Rivières.\" To be sold at the Bécancour Registry Office, Division No.1, 3050 Nicolas-Perrot Avenue.Bécancour, on WEDNESDAY, the NINETEENTH day of FEBRUARY, 1975, at THREE o'clock in the afternoon.Fernande Turgeon, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Trois-Rivières, December 9, 1974.59398 Errata Errata IMPERIAL SCHOOL FURNITURE (QUEBEC) LIMITED L'AMEUBLEMENT SCOLAIRE IMPERIAL (QUEBEC) LIMITEE Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis d'abandon de charte de la compagnie « IN-PERIAL SCHOOL FURNITURE (QUEBEC) LIMITED \u2014 L'AMEUBLEMENT SCOLAIRE IMPERIAL (QUEBEC) LIMITEE », paru le 30 novembre 197*, à la page 8979 du numéro 48 de la Gazette officielle du Québec, en y remp'açant à la version ang aise le mot « INPERIAL » par « IMPERIAL >, de manière que le nom se lise ainsi: « IMPERIAL SCHOOL FURNITURE (QUEBEC) LIMITED \u2014 L'AMEUBLEMENT SCOLAIRE IMPERIAL (QUEBEC) LIMITEE ».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59375-e 2601-69 MAGNY TRANSPORT (INCORPOREE) Prenez note que l'avis de situation de domicile légal de la compagnie « MAGNY TRANSPORT (INCORPOREE) », paru le 31 août 1974 à la page 6099 du numéro 35 de la Gazette officielle du Québec, est nul et de nul effet.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59375-0 7092-40 IMPERIAL SCHOOL FURNITURE (QUEBEC) LIMITED L'AMEUBLEMENT SCOLAIRE IMPERIAL (QUEBEC) LIMITEE Notice is given that under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice of surrender of charter of \"INPERIAL SCHOOL FURNITURE (QUEBEC) LIMITED \u2014 L'AMEUBLEMENT SCOLAIRE IMPERIAL (QUEBEC) LIMITEE\", published in the Québec Official Gazette, number 48, dated November 30.1974.on page 8979, by replacing in the English version the word \"INPERIAL\" by \"IMPERIAL\", in order that the name read as follows: \"IMPERIAL SCHOOL FURNITURE (QUEBEC) LIMITED \u2014 L'AMEUBLEMENT SCOLAIRE IMPERIAL (QUEBEC) LIMITEE\".59375 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.2601-69 MAGNY TRANSPORT (INCORPOREE) Please note that the notice of location of legal domicile of \"MAGNY TRANSPORT (INCORPORÉE) ', published in the Québec Official Gazette, number 35, dated August 31, 1974, on page 6099, is null and void.Pierre Desjahdins.Director of the Companies Service.59375 7092-10 9550 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 21, 19U, Vol.106, No.51 EQUIPEMENT H.CARDINAL LTEE et sa version anglaise H.CARDINAL EQUIPMENT LTD.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, sous l'autorité de l'article 12 de la Loi des compagnies, donne avis qu'il a corrigé le 19 novembre 1974, les lettres patentes émises le 27 août 1974.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59375-0 1369-4658 EQUIPEMENT H.CARDINAL LTEE et sa version anglaise H.CARDINAL EQUIPMENT LTD.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, under section 12 of the Companies Act, gives notice that he corrected on November 19, 1974, the letters patent issued on August 27, 1974.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.59375 1369-4658 LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VOLTEL INC.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis de lettres patentes, en date du 29 octobre 1974, de la compagnie « LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VOTEL INC.», paru le 30 novembre 1974 à la page 8969 du numéro 48 de la Gazette officielle du Québec, en y remplaçant dans ledit nom le mot « VOTEL » par « VOLTEL », de manière que le nom se lise ainsi: « LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VOLTEL INC.».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59375-0 1370-1859 LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VOLTEL INC.Notice is given that under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice of letters patent, dated October 29, 1974, of \"LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VOTEL INC.\", published in the Québec Official Gazette, number 48, dated November 30.1974, on page 8969, by replacing in said name the word \"VOTEL\" by \"VOLTEL\", in order that the name read as follows: \"LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VOLTEL INC.\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.59375 1370-1859 WILLIAMS' INCORPORATED Avis est donné qu'en vertu de la première paitie de la Loi des compagnies, il a plu au ministie des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis de changement d'administrateurs de la compagnie « WILLIAM'S INCORPORATED », paru le 30 novembre 1974 à la page 8980 du numéro 48 de la Gazette officielle du Québec, en y remplaçant dans ledit nom le mot « WILLIAM'S » par « WILLIAMS' », de manière que le nom se lise ainsi: « WILLIAMS' INCORPORATED »./-c directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59375-0 3044-49 WILLIAMS' INCORPORATED Notice is given that under Part I of the Companies Act, if has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice of change of directors of \"WILLIAM'S INCORPORATED\", published in the Québec Official Gazette, number 48, dated November 30, 1974, on page 8980, by replacing in the said name the word \"WILLIAM'S\" by \"WILLIAMS'\", in order that the name read as follows: \"WILLIAMS' INCORPORATED\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.59375 3044-49 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SI décembre 1974, 106' année, n° 51 9551 INDEX No 51 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES COOPERATIVE ASSOCIATIONS Club coopératif populaire de consommation de Saint-Edouard (Formation).9430 Coopérative d'habitation St-Rocli I (Formation).9431 Coopérative de loisirs de plein air La Bàtarde-sur-Chaudière (Formation).9430 AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Conseil régional de pastorale de la liasse-Ville de Québec (L.P.).9424 Conseil régional de pastoiale de Charlevoix (L.P.).9423 Conseil régional de pastorale de La Chaudière (L.P.).9423 Conseil régional de pastorale des Laurentides (L.P.).9424 Conseil régional de pastorale de Limoilou (L.P.).9421 Conseil régional de pastorale de Lorette (L.P.).9421 Conseil régional de pastorale de Lotbinière et des Bois-Francs (L.P.).9421 Conseil régional de pastorale de Louis-Hébert (L.P.).9422 Conseil régional de pastorale Orleans (L.P.).9422 Conseil régional de pastorale du Plateau (L.P.).9422 Conseil régional de pastorale de Portneuf (L.P.).9422 Conseil régional de pastorale de la région de L'Amiante (L.P.).9423 Conseil régional de pastorale de la Rive-Sud (L.P.).9423 GAC Private Brands Limited (Société de prêts et placements-Loan and Investment Societies Act).9424 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Accordés: Granted: Cartier, Mary Margaret Géraldine Susan.9431 Laçasse, Marie Blanche Anne Louise.9431 Rivard, Jean.9431 Sutton, Alain.9431 Sutton, Moise.9432 Treiser, Murray Frank.9432 Ustiniuk, Michel.9432 Demandes: Applications: Bilodeau, Serge.9419 Bloomfield, Nila Margaret Graham.9420 Cook, Joseph Archille.9420 Courtemanche, Aline.9421 Hum, Paul.9420 Laurier, Jean.9420 Souillac, Léon Simon.\u2022\u2022\u2022\u2022 9420 COMMISSIONS COMMISSIONS Commission Québec Transport des transports du Québec Commission Avis de la Commission « proprio motu »____ 9498 Notice \"proprio motu\" by the Commission 9498 Avis de décisions rendues.9456 Notice of decisions rendered.9456 Avis d'introduction de requêtes.9499 Notice of submission of applications.9499 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, December 21, 1974, Vol.10G, No.51 9552 COMPAGNIES EXTRA-PROVINCIAL ÉTRANGÈRES COMPANIES Permis: Licenses: Foothills Catering Ltd.9415 Refco-Montreal, Inc.9415 COMPAGNIES - COMPANIES LOI DES ACT Abandon Surrender de charte of Charter Ameublement scolaire Imperial (Québec) limitée (Correction) (L').9549 Bressée (Frank) inc.9409 Imperial School Furniture (Québec) Limited (.Correction).9549 Administrateurs Directors (Article 84) {Section 84) A.P.M.Inc.9410 Abiexlnc.9410 Artistic Wire Works Ltd.9410 Bourque Automotive Inc.9410 Centre de mode Lauren tien ltée.9410 Club Sales & Agencies Ltd.9410 Dubois-Stewart Inc.9410 Jacques (C.A.) inc.9410 Laurentien Fashion Centre Ltd.9410 Lorraine Food Services Inc.9410 Mosaic Investment Ltd.9410 Placements Harvey inc.9410 Placements Mosaïque ltée (Les).9410 Rochelom Mines Ltd.(N.P.L.).9410 Rochelom Mines ltée (L.R.P.).9410 Services alimentaires Lorraine inc.(Les) .9410 Williams' Incorporated (Correction).9550 Changement de nom Change of name Aircraft Welding and Sheet Metals Co.Limited.9411 Club de Golf des Grands-Coteaux inc.9411 Compagnie de Coke Lasallc (La).9411 Compagnie Impériale de quincaillerie décorative.9411 Compagnie de tôlerie et soudage pour avion limitée.9411 Ferauto inc.9411 G.L.P.Software Systems Support Ltd.9411 Imperial Decorative Hardware Co.9111 Isabelle Productions Inc.9411 Lainesse & Masson inc.9411 Lasalle Coke Company.9411 Marcoux (Jerry) inc.9411 Perreault (J.et R.) inc.9411 Productions Isabelle inc.(Les).9411 Restaurant St-Germain.9411 Support de systèmes d'informatique G.L.P.ltée.9411 Demandes d'abandon Applications for de charte Surrender of Charter Associated Food Consultants Ltd.9414 Bonaventure Hockey School Inc.9414 Ecole de hockey Bonaventure inc.(L').9414 Entreprises X.À.F.limitée (Les).9414 Fontaine fourrures ltée.9414 Progrès 9.inc.9415 Progress 9, Inc.9415 Vermeulen (Jos) inc.9415 Domicile légal Legal domicile (Article 30) (Section 30) Aris Beauty Salon Ltd.9412 Big Town Copper Mines Ltd.(N.P.L.).9412 Bisson automobiles inc.9412 Boutin Sanitary Services Inc.9413 Canoe Investments Inc.9412 Club Enfin.941* Club Murray inc.9412 Construction Tcrpel ltée.9412 Côté (Roger) Realties Inc.9413 Daoust (Marcel) Petroleum Limited.9412 Distribution à l'automobiliste Longueuil inc.9412 Doranda inc.9412 Editions de l'hydrocéphale entêté inc.(Les) .9412 Elkton Enterprises Inc.9412 EmperClub.9412 Entreprises Elkton inc.(Les).9412 Entreprises Lortie inc.(Les).9412 Entreprises Vaudlare ltée (Les).9412 Fournier (Willie) & Ass.inc.9412 Gagnon & Pelletier inc.9412 Gestion Pima limitée.9413 Gilmar Dress Inc.9413 Hialeah Restaurant Inc.9413 Immeubles Roger Côté inc.9413 Joliette décor inc.9413 Kedo Investment Ltd.9413 Maçonnerie Longueuil inc.9413 Magny Transport (Incorporée) (Annulation).9549 Maison du baril rustique inc.9413 Malartic Finance Corporation.9413 Marotte & Samson inc.9413 Pavage Abénakis ltée.9413 Pima Management Limited.9413 Placements Canoë inc.(Les).9412 Poirier (François) limitée.9413 Restaurant Hialeah inc.9413 Restaurant La Maisonnée (1974) inc.9413 St.James Literary Society.Inc.(The).9413 Services sanitaires Boutin inc.9413 Systèmes d'alarme Boisbriand ltée.9413 Tranchemontagne (C.X.) inc.9413 Tyrol Enterprises Inc.9413 Tyrol entreprises inc.9413 Vaudlare Enterprises Ltd.9312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1974, 106' année, n' 51 9553 Lettres patentes Letters Patent (1-partie) (Parti) Aéro-climatisation Confort ltée.9399 Air climatisé Ste-Geneviève inc.9399 Aménagements du Fief inc.(Les).9399 Aménagement Saranac ltée.9399 Amusements Labbee inc.9399 Antennes Vidéo inc.939
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.