Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 11 (no 2)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1975-01-11, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" AVIS JURIDIQUES PARTIE 1 JURIDICAL NOTICES 107e ANNEE 11 JANVIER 1975 NO 2 OFF A11E8 G3/ PTIE1 EX.2 4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC \t\t\t\t\tL 71\t^ il-\t\t._11_.\t\u20141\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° 2 91 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 parait le samedi matin et contient des a vis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Quebec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Quebec, CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Official PublMer 02 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 85 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Période - d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, S20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1R 4Y7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Quibee Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1R 4Y7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° S 93 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Compagnies \u2014 Loi des Companies Act\t\t\t\t\t Abandon de charte Surrender of Charter\t\t\t\t\t Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Com-il a accepté l'abandon de la charte de: panies Act, he has accepted the surrender of the charter of:\t\t\t\t\t Incorporation Nom / Name Date\t\t\tDissolution Date\t\t ALIMENTATION SIMARD LTEE.03 5397-64\t12\t64\t20\t12\t71 ASSOCIATION DES MECANOS DE LA MAURICIE INC.30 37-70\t01\t70\t30\t12\t74 ASSURANCES P.LOUIS LEPAGE LTEE.02 5868-69\t01\t70\t30\t12\t74 BEVERLY CORPORATION.07 3370-63\tOS\t63\t30\t12\t74 PAUL BOLDUC INC.25 2753-64\t06\t64\t03\t01\t76 4693-65\t10\t65\t30\t12\t74 BUREAU D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DES SCHICK-SHOCKS 09 INC.1545-64\t04\t64\t20\t12\t74 10023-55\t01\t56\t20\t12\t74 DAWSON INVESTMENT CORP.11 13078-57\t10\t57\t03\tni\t76 DECARIE CONSTRUCTION LTEE - LTD.17 1134-0379\t09\t63\t27\t12\t74 3338-71\t06\t71\t27\t12\t71 AJUSTEURS DE L'EST LTEE 12226-56\t117\t66\t30\t12\t74 HOPITAL GENERAL DE JOLIETTE.08 HOP.2296-70\t07\t70\t27\t12\t74 L & W REALTIES LTD.22 795-65\t02\t66\t30\t12\t74 MUSCOOT LIMITED.23 2483-37\t09\t37\t30\t12\t74 THOMAS J.MAHON, LIMITED.23 10361-61\t01\t61\t04\t10\t74 GAETAN MONTREUIL INC.01 5075-65\t12\t65\t16\t11\t74 OEUVRE DES LOISIRS DE LA S.S.J.B.DE RIVIERE BLANCHE 01 INC.5243-65\t12\t66\t30\t12\t71 01 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 \u201e , \u201e Incorporation Dissolution Nom / Name Date Date HARRY E.PARKS LIMITED.22 02 67 20 12 74 1118-8026 PAVAGE REGIONAL INC.20 01 66 27 12 74 REGIONAL PAVING INC.210-66 RAMSAY'S EXPRESS MOVING & STORAGE LTD.10 09 62 03 01 76 13648-62 ROBERVAL ENTERPRISES LTD.30 01 45 30 12 74 LES ENTREPRISES ROBERVAL, LTEE 1360-45 ROSITA HOSIERY MILLS LTD.23 07 53 30 12 74 16012-53 SOMECO COLBERT INC.20 11 67 10 01 75 4772-67 TAVERNE RADISSON INC.06 05 63 30 12 74 1948-63 VANIX INC.30 04 63 06 01 75 1914-63 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins, 69509-o Pierre Desjardins.69509-o Director of the Companies Service.Lettres patentes supplémentaires Supplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the il a accordé des lettres patentes supplémentaires à: Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Incorporation L.P.S./ S.L.P.Modifications Nom / Name Date Date Changes AUTO DRUGSTORE (QUEBEC) LTD.16 02 72 10 12 74 Modifiant le capital / Altering the capital 717393 BAYVIEW HOSPITAL INC.30 11 61 04 12 74 Modifiant le capital / Altering the capital 16817-61 MURRAY G.BULGER & ASSOCIES (QUEBEC) 20 06 69 25 10 74 Modifiant le oapital / Altering the capital LTEE 3112-69 COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT AGRI- 20 03 74 25 10 74 Modifiant le capital / Altering the capital COLE ROUVILLE LTEE ROUVILLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT COMPANY LTD.1367-3173 COMPTOIR AGRICOLE ST-ROCH INC.17 06 70 02 12 74 Etendant les pouvoirs/Extending the powers 1201\u20146218 CORPORATION DE L'HOPITAL GENERAL 12 08 64 20 02 74 Augmentant la valeur des biens immobi- DE CHANDLER liers / Increasing the value of immoveable Hop : 1169\u201464 property ELECTRO MESURE, INC.12 07 63 29 10 74 Modifiant le capital / Altering the capital 1113-5878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° 3 Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes EQUIPEMENT L.V.R.INC.02 08 714057 ESTRICERAM INC.07 06 737317 FONDATION FOURNIER-ETHIER INC.07 07 3481-71 GENDRON LEFEBVRE INC.15 12 5713-64 LES INDUSTRIES ALARIE DE MALARTIC, 02 02 LIMITEE 1169-6341 LISTEL CORPORATION.24 07 3623-69 MONTREAL MEAT BROKERS INC.08 04 COURTIERS EN VIANDE DE MONTREAL INC.1604-69 PAPETERIE J.LEO GAGNON INC.08 06 732662 LES PECHEURS ET CHASSEURS SPORTIFS 12 11 DU LAC ST-LOUIS INC.et sa version anglaise LAKE ST.LOUIS ANGLERS AND HUNTERS INC.7758-46 LES PLACEMENTS LA TOSCANE LTEE____ 17 06 TUSCANY HOLDINGS LTD.1357-2714 SHAWNEE MINES & OILS (CANADA) 19 07 LIMITED 3820-71 71 02 12 74 Etendant les pouvoirs I Extending the powers 73 02 12 74 Modifiant le capital / Altering the capital 71 04 11 74 Modifiant les pouvoirs / Modifying the pow- 64 06 11 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant les dispositions des lettres patentes / Modifying the provisions of the letters patent 66 05 12 74 Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patents 69 09 12 74 Modifiant quelques dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent 69 29 10 74 Modifiant le capital / Altering the capital 73 29 10 74 Ancien nom / Former name LES PAPETIERS DU NORD-OUEST DU QUEBEC INC.46 29 10 74 Ancien nom / Former name LAKE ST.LOUIS ANGLERS.INC.LES PECHEURS SPORTIFS DU LAC ST-LOUIS INC.74 16 10 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Etendant les pouvoirs / Extending the powers 71 19 11 74 Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent 59509-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59509-q Pierre Desjardins.Director of the Companies Service.Lettres patentes (1™ partie) Letters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de ia Loi des compagnies, il a accordé des iettres patentes constituant en corporation: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date LES APPAREILS MENAGERS G.D.INC.1359-4742 ATELIER DE DEBOSSELAGE ST-JOSEPH INC.et sa version anglaise ST-JOSEPH BODY WORK SHOP INC.1359-4569 Cowansville.01 10 74 683, boulevard St-Joseph, Hull.01 10 74 96 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date P.ROBERT BERNIER INC.1360-2594 BOUTIQUE ANDRE BIBEAU INC.1360-1760 BOUTIQUE DE CADEAUX VICTORIA INC.and its English version VICTORIA GIFT SHOP INC.1360-1521 LES BRASSERIES PONT-ROUGE INC.1360-3626 CARROSSERIE GONNOT LTEE.et sa version anglaise GONNOT AUTO BODY SHOP LTD.1370-1602 COMPAGNIE FILTREX INC.et sa version anglaise FILTREX CO.INC.1369-5168 COMPAGNIE DE REBUTS G.D.LTEE.et sa version anglaise G.D.WASTE-PAPER CO.LTD.1370-2402 CONSTRUCTION LEBOIS, BEDFORD (C.L.B.) LTEE.1359-8347 COUVREUR E.L.SAVOIE LTEE.et sa version anglaise E.L.SAVOIE ROOFING LTD.1370-2394 LES CREATIONS S.E.C.INC.1369-5838 DISTRIBUTION VISTEK INC.1360-1752 ENTREPRENEUR GENERAL H.TOUSIGNANT LTEE.1359-9311 ENTREPRISES DE DEGELEMENT SEPT-ILES INC.1360-3659 LES ENTREPRISES D'ELECTRICITE A.BEAUDRY INC.1359-5640 LES ENTREPRISES F.HEBERT INC.et sa version anglaise F.HEBERT ENTERPRISES INC.1370-4200 LES ENTREPRISES L.O.R.Y.INC.1360-1232 LES ENTREPRISES M.CAMILLE INC.1359-7463 LES ENTREPRISES N.A.M.INC.1360-1844 LES ENTREPRISES DE REBUTS L.G.D.INC.1359-5566 FINITION DE PLANCHER J.B.INC.et sa version anglaise J.B.FLOORING INC.1357-7929 917, Bourlamaque, Québec.156 Route 5, Princeville.5865, avenue Victoria, Montréal.100, boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge.Route 8, Angers.13 11 74 08 11 74 07 11 74 20 11 74 25 10 74 8679.8e Avenue, Saint-Michel.30 08 74 6777, Place Pasquale-Gagnon, Saint-Léonard.Bedford.1275, Barré, Montréal.627, rue Précieux Sang, Joliette.Repentigny.Palmarolle, Abitibi-Ouest.Sept-Iles.15, rue Jogues, Hull.Saint-Bruno.1698, 3e Avenue, Québec.Cowansville.Québec.43, rue Robinson nord, Granby.2940, rue Prieur, app.1, Montréal.31 10 74 21 10 74 31 10 74 09 09 74 08 11 74 25 10 74 20 11 74 07 10 74 18 11 74 06 11 74 17 10 74 11 11 74 07 10 74 12 07 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 janvier 1975, 107' année, n° 2 97 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date GESTION BLANDER LTEE.and its English version BLANDER MANAGEMENT LTD.1360-0085 HOTEL LE MANOIR RIVIERE-DU-LOUP INC.1359-9261 7480, avenue Wavell, Côte Saint-Luc.30 10 74 LES IMMEUBLES JACDEVIL INC.1359-9188 LES IMMEUBLES LEMAY & PRUNEAU LTEE.1358-3919 IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS DE LINGOTS CANDOR INC.and its English version CANDOR BULLION IMPORTERS AND EXPORTERS INC.1370-3038 LES INDUSTRIES CARROUSEL INC.1360-5324 INDUSTRIES ULTEC INC.et sa version anglaise ULTEC INDUSTRIES INC.1370-2758 INVESTISSEMENT CANADA INTERNATIONAL INC.et sa version anglaise INVEST CANADA INTERNATIONAL INC.1359-8859 LECLERC & LEDOUX INC.1358-4909 LEPINE-CLOUTIER LTEE.1360-7452 LOCATION FOURNIER INC.1360-0176 MONDIMMOBILE LTEE.1360-1703 LES PLACEMENTS S.L.G.R.LTEE.and its English version S.L.G.R.INVESTMENTS LTD.1360-1455 ROUMIAN INC.1360-6082 SERVICE DE MOTEURS E.J.INC.et sa version anglaise E.J.MOTORS SERVICE INC.1360-0051 LE SERVICE D'ORGANISATION FONCTIONNELLE DES GROUPES S.O.F.O.G.INC.1368-9072 LA 80CIETE PLACIM INC.1360-3121 SOCIETE SOG8ABEC LTEE.1370-1116 DAVID TAFLER INC.1370-3687 F.H.TREMBLAY & FILS INC.1360-2479 24, de la Cour, Rivière-du-Loup.13 11 74 341, rue St-Dominique, Jonquière.25 10 74 5, rue St-Jean-Baptiste, Pointe- 09 08 74 Gatineau.1255, rue Université, suite 917, 06 11 74 Montréal.225, rue St-Jacques, suite 120, Montréal 29 11 74 6155, Transcanadienne, Saint-Laurent.04 11 74 33, rue Blainville ouest, suite 305, Sainte-Thérèse.23 10 74 1225, rue St-Louis, Saint-Joseph-de- 28 11 74 Saint-Hyacinthe.715, St-Vallier est, Québec.11 12 74 48, Kennedy, Levis.20 11 74 Montréal.08 11 74 Montréal.07 11 74 1057, rue Chaumont, Sillery.04 12 74 Saint-Georges.30 10 74 1570, Place Gaudet, Trois-Rivières____ 29 08 74 1277, De Callières, Québec.18 11 74 50, Place Crémazie, Montréal.22 10 74 1616, Jules-Poitras, suite 207, Montréal 13 11 74 Québec.13 11 74 OS QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1976, Vol.107, No.2 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date VENTE DE CAMIONS DUNLOP LTEE.and its English version DUNLOP TRUCK SALES LTD.1358-1651 LES VENTES A COMMISSION DE LACHUTE (1974) INC.et sa version anglaise LACHUTE COMMISSION SALES (1974) INC 1359-6698 VITRERIE VAILLANCOURT INC.1360-5423 350, chemin Mountain, Lucerne.16 09 74 Route Rurale 1, Grenville.11 10 74 Victoriaville.02 12 74 Le directeur du service des compagnies, 59509-0 Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 59509-o Director oj the Companies Service.Changement de nom\tChange of Name Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a approuvé les règlements de changement de nom suivants:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has approved the by-laws changing the name of: Ancien nom Incorporation Nouveau nom / New name Former name Date\t LES ALIMENTS RICHELIEU INC.LES RECEPTIONS RICHELIEU INC.27 06 69 et sa version anglaise RICHELIEU ALIMENTS INC.1153-2702 AMENAGEMENT IMMOBILIER SATELLITE SATELLITE REALTIES AND DEVELOPMENT 29 03 62 INC.INC.et sa version anglaise SATELLITE REALTIES AND DEVELOPMENT INC.11371-62 BAS A CHAUSSETTES GINA LTEE.FABRICANT DE BAS GINA LTEE 06 03 74 et sa version anglaise GIN A HOSIERY LTD.GINA HOSIERY MILLS LTD.1367-4346 LE BLUE-JEAN DE L'OUEST INC.LES MODES NOUS DEUX INC.07 02 74 1367-4973 LA BRASSERIE LE GAULOIS INC.LE GROUPE ATLANTIDE INC.19 12 72 726684 COMPAGNIE PHARMACEUTIQUE VITA LTEE.COMPAGNIE PHARMACEUTIQUE VITA LTEE.05 06 64 et sa version anglaise VITA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD.2689-64 COMPAGNIE UNIFIEE DE BEACONSFIELD- BEACONSFIELD COMBINED APPEAL 06 02 61 KIRKLAND INC.INCORPORATED et sa version anglaise BEACONSFIELD-KIRKLAND COMBINED APPEAL INC.15526-60 COMPO-IMPRO INC.LE JOURNAL LA VIE (1969) LTEE.09 12 69 5989-69 EDITIONS THEMIS INC.REVUE JURIDIQUE THEMIS INC.20 09 68 4276-68 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, rc° 8 99 Nouveau nom / New name Ancien nom Former name Incorporation Date EMBALLAGES BILTWEEL LTEE.et sa version anglaise BILTWELL CONTAINERS LTD.10446-55 ENTREPRISES OCTOSTOP INC.et sa version anglaise OCTOSTOP ENTERPRISES INC.1965-69 LES ENTREPRISES « SUN GLOW » INC.et sa version anglaise \"SUN GLOW' ENTERPRISES INC.1123-4598 FECO INC.723394 GREGOIRE, BERTHIAUME, PAQLETTE.RACICOT SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 1154-1971 IMMEUBLES LUMI INC.1021-71 LES INDUSTRIES DE COUTURE PUCCINI LTEE 1369-1571 MAISONNERIE INC.734604 ENA ROBERGE INC.1194-6449 SHALINSKY.BIERBRIER, PERELMAN A GOLDSTEIN INC.14836-62 VENTILATION CHAUFFAGE PLOMBERIE G.AUDY LTEE et sa version anglaise G.AUDY PLUMBING HEATING B1TLWELL CONTAINERS LTD.17 02 65 ENTREPRISES JEAN A.VEZINA LTEE.01 05 69 SUN-GLOW NORTEX INC.02 03 54 LEFRANCOIS & FRERES INC.15 06 72 JEAN GREGOIRE ET ASSOCIES SOCIETE A 10 03 71 RESPONSABILITE LIMITEE IMMEUBLE ST-DONAT INC.28 01 71 Si'.DON AT REAL ESTATE INC.LES MODES ROBBY-LEN LTEE.30 07 74 and its English version ROBBY-LEN FASHIONS LTD.MAURICE TRUCHON INC.19 10 73 PARE-CHOCS DE L'EST INC.27 01 70 EASTERN BUMPERS INC.SHALINSKY, BIERBRIER & PERELMAN INC.18 12 62 PLOMBERIE, CHAUFFAGE.VENTILATION GERRV LTEE GERRY'S PLUMBING, HEATING, VENTILATION LTD.01 05 74 VENTILATION LTD.1356-2160\t Le directeur du service des compagnies, 59509-o Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 59509-o Director of the Companies Service.Siège social (Article 84)\tHead office (Section 84) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les noms suivent ont changé leur siège social tel qu'indiqué ci-après.\tNotice is hereby given that the companies and corporations whose names follow have changed their head office as indicated hereinafter.Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Siège social Head office Date Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address AMOS AVIATION LIMITED.1181-0660 BARBEL TRANSPORT INC.2498-66 16 05 63 Saint-Mathieu (Abitibi).Amos.04 08 66 380.Desrochers, Vanier.1, 1ère Rue, Gagnon. 100 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address BINOR DISTRIBUTORS LTD.LES DISTRIBUTEURS BINOR LTEE 729023 21 09 72 236, rue Elm, Saint-Lambert.BON-AIRE BEDDING MFG.LTD.20 11 63 Montréal.1115-5512 CAMEO FABRICS LTD.10604-61 08 02 61 Montréal.CANATECH INC.736567 CENTRAL TRUCK LINES LTD.1174-4315 JACQUES CHARETTE ET ASSOCIES LTEE.et sa version anglaise JACQUES CHARETTE AND ASSOCIATES LTD.1195-8964 13 03 73 606.de Gaspé (Ile des Soeurs), Verdun.16 09 49 1265.7e Rue.Val-d'Or.02 03 70 2.carré Westmount, Westmount.1, Place Ville-Marie, suite 3635, Montréal.4753, boulevard Des Grandes Prairies, Saint-Léonard.515, rue Deslauriers, Saint-Laurent.796, rue Halpern, Dorval.6600, Côte St-François, Saint^Laurent.673, boulevard St-Joseph, Hull.CHAUSSURES SOREL-TRACY INC.1204-3188 27 11 70 Tracy.45, rue St-Georges, Sorel.CHERRY RIVER CHALETS INC.4303-66 COMPAGNIE DE RECHERCHE « BACTO-CHEM » LTEE BACTO CHEM RESEARCH CO.LTD.13478-67 CONTINENTAL HOME DECORATING & UPHOLSTERING CO.509-71 CORPORATION CON-VEC LTEE.CON-VEC CORPORATION LTD.720477 24 10 66 Route Rurale numéro 2, Magog.12 11 57 Sainte-Anne-de-Bellevue.01 02 71 4180, Courtrai, app.3, Montréal.26 01 72 Laval.YVAN COURNOYER INC.4594-70 21 10 70 20036, Place Wilson, Baie-d'Urfée.2075, rue Melba, Saint-Bruno-de-Montarville.3105, rue Fendall, Montréal.5460, nie Royalmount, Mont-Royal.1483, rue Lapointe, Val-d'Or.1700, rue Norman, Lachine.ARTHUR DIAMOND INC.3022-64 DOMAINE DES HAUTES LAURENTIDES INC.746321 DUMONT INC.6897-50 LES EDITIONS FLAMMARION LTEE.1355-4357 FOB EC INC.3972-65 FORTIN (BANDAG) LTEE.FORTIN (BANDAG) LTD.1166-1717 03 07 64 2050, rue Mansfield, Montréal.05 02 74 200, Fort St-Louis, Boucherville.10 08 60 5850, chemin Côte de Liesse, Montréal.01 04 74 Montréal.07 09 65 Montréal.02 11 66 Trois-Rivières.G.L.R.INC.676-70 06 02 70 Québec.GENERAL TANK MAINTENANCE LTD.1113-3022 22 06 61 5435, rue Angers, Montréal.66, avenue Sunnyside, Westmount.Saguay.6600, Côte St-François, Saint-Laurent.360, boulevard Lebeau, Saint-Laurent.8081, rue de la Seine, Anjou.100, Arnaud, Sainte-Foy.1781, routn de l'Aéroport, Anciennc-Lorette.602, boulevard 9C, Sninte-Catherine-d'Alexandria. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° S 101 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Siège social Head office Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address HAMER SERVICE LTEE.11 11 64 Montréal.6905, Trans-Canada Hwy., 1125-8001 Saint-Laurent.LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES MEGA 05 04 73 8561, De Louresse, Anjou.7078, rue St-Laurent, LTEE Monréal.MEGA ELECTRIC INSTALLATIONS LTD.736763 LALLIER AUTOMOBILE INC.27 03 63 3941, 9e Rue, Chomedey, 597.Notre-Dame, 1141-1584 Laval.Repentigny.MATECONOMIE LTEE.21 04 71 210, rue St-Michel, Sainte- 85, de Vaudreuil, 1209-6079 Emélie-de-L'Energie.Boucherville.NORM AN RENTAL INC.15 12 72 I.ongueuil.5105.nie Ramsay.LOCATION NORMAN INC.Saint-Hubert.726630 LES PLACEMENTS LA MALBAIF LIMITEE.31 10 69 800, Place Victoria, 2, Place Québec, Québec.LA M ALB A IE INVESTMENTS LIMITED suite 2011, Montréal.1193-2878 TELMARK NICKEL CORPORATION 14 05 71 Montréal.122, Se Rue, Val-d'Or.(No personal liability) 2578-71 THETFORD TRANSPORT LIMITEE.07 02 55 9055, boulevard l'Acadie, 1829, boulevard Smith 1167-7309 Montréal.nord, Thetl'ord Mines.VETEMENTS FORESTIERS V.F.LTEE.09 05 73 1.rue des Pins, 305, Route Rurale, numéro 732123 Port-Cartier.2, Saint-Charles-des- Grondines.VINCENT LTEE.14 08 53 Montréal.1500, boulevard Jules- VINCENT LTD.Poitras, Saint-Laurent.19128-53 59509-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59509-O Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Administrateurs (Article 84) Directors (Section 84) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les noms suivent ont modifié le nombre de leurs administrateurs tel qu'indiqué ci-après.Notice is hereby given that the companies and corporations whose names follow have changed the number of their directors as indicated hereinafter.Nom de la compagnie Name of company Date de constitution Date of incorporation Nombre d'administrateurs Number of directors Ancien nombre Previous number Nouveau nombre New number ABITIBI TRUCK LINE LIMITED.11 07 65 11744-55 MARC CARRIERE LIMITEE.27 08 62 11305-52 CENTRAL TRUCK LINES LTD.16 09 49 1174-4315 CHAMPLAIN SEPT-ILES EXPRESS INC.29 10 71 715781 102 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.S Nom de la compagnie Name of company\tDate de constitutions Date of incorporation\tNombre d'administrateurs Number of directors Ancien nombre Nouveau nombre Previous number New number\t CHAMPLAIN SEPT-ILES EXPRESS INC.715781\t29 10 71\t5\t3 CHERRY RIVER CHALETS INC.4303-66\t21 10 66\t4\t3 COMACT INC.1029-38\t11 06 38\t6\t7 COMMUNICATION VENTES ET SERVICE C.S.S.INC.C.S.S.COMMUNICATION SALES AND SERVICE INC.73751S\t28 06 73\t3\t4 LA COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE LTEE EUROPEAN FINANCIAL COMPANY LTD.1354-9332\t15 03 74\t3\t4 1159-4942\t28 12 62\t5\t3 5897-60\t10 08 60\t6\t3 EQUIPEMENT HYDRAULIQUE BOREAL INC.et sa version anglaise BOREAL HYDRAULIC EQUIPMENT INC.1357-3944\t25 06 74\t3\t4 LES IMMEUBLES VAL-MARTIN LTEE.VAL-MARTIN REALTIES LTD.47636-53\t03 11 53\t4\t3 3457-69\t11 09 69\t3\t6 1209-6079\t21 04 71\t3\t7 716800\t09 12 71\t3\t8 A.A.NORRIS & CO.LTD.11234-55\t30 04 55\t3\t4 ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL.MONTREAL SYMPHONY ORCHESTRA 3485-39\t29 06 39\t22\t9 ST-GEORGES EXPRESS (1962) LIMITEE.500-63\t27 12 62\t6\t3 1431-65\t26 04 65\t3\t6 13499-56\t14 03 67\t10\t0 SOCIETE TERVECO LTEE.725519\t03 10 72\t3\t7 SUPERMARKET FASHIONS INC.2780-71\t27 06 71\t4\t3 VOYBEC INC.1355-5735\t27 02 74\t6\t3 Le directeur du service des compagnies, 59509-o Pierre Desjardins.59509-0\t\tPierre Desjardins, Director of the Companies Service.\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° S 103 Lettres patentes (3e partie) Letters Patent (Part III) Le ministre des institutions coopératives donne avis, qu'en de la Loi des compagnies, il a constituant en corporation:\tfinancières, compagnies et vertu de la troisième partie accordé des lettres patentes\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating: Nom / Name\t\tIncorporation Siège social / Head Office Date L'ASSOCIATION DES POMPIERS DE ST-DAMIEN DE BRANDON-BERTHIER INC.1359-8966 CARREFOUR POUR ELLE.1359-5541 CENTRE DE PRIERE L'ALLIANCE INC.1359-6655 CLUB ARGENTIN DE MONTREAL.1369-9517 CLUB ATHLETIQUE LES CRACS DE MONTREAL.1360-1786 CLUB DE MOTO-NEIGE ST-ZOTIQUE INC.1359-7588 CLUB OPTIMISTE SENNETERRE, QUEBEC.1359-7604 CLUB SPORTIF AUX QUATRE BONNES GRIFFES.1360-1372 CLUB DE TENNIS LA SAISON INC.1359-2761 COMMUNICATIONS BASSE-VILLE.1359-4320 LES PROPRIETES DES AINES DU LAC ST-LOUIS INC.and its English version LAKE ST-LOUIS SENIOR CITIZENS' PROPERTIES INC, 1359-4866 RESIDENCES BORD DE L'EAU DE LONGUEUIL, INC.1370-2163 41 route 43, (Hôtel de Ville) Saint- 24 Damien.10 74 1215, boulevard Ste-Foy, Longueuil.31 10 74 Trois-Rivières.11 10 74 3956, St-Laurent, 1er étage, Montréal.07 10 74 Montréal.08 11 74 Saint-Zotique.27 09 74 Senneterre.17 10 74 1260, De Lanaudière, Joliett*.08 11 74 957, rue Dunlop, Outremont.11 11 74 Québec.30 07 74 Pointe-Claire.02 10 74 2522, rue Delorimier, Longueuil.30 10 74 59509-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardinb.59509-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Demandes d'abandon de charte Applications for Surrender of Charter FERRONNERIE CHARBONNEAU, LTÉE CHARBONNEAU HARDWARE, LTD.Prenez avis que «FERRONNERIE CHARBONNEAU, LTEE \u2014 CHARBONNEAU HARDWARE, LTD.\" demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 17 décembre 1974.Les procureurs de la compagnie, Létourneau, Forest, Raymond, 59538-o Létourneau & Roy.FERRONNERIE CHARBONNEAU, LTÉE CHARBONNEAU HARDWARE, LTD.Notice is hereby given that \"FERRONNERIE CHARBONNEAU.LTEE \u2014 CHARBONNEAU HARDWARE, LTD.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, December 17th, 1974.Létourneau, Forest, Raymond, Létourneau & Roy, 59538-0 Attorneys for the company. 104 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 MORULA INC.Prenez avis que la compagnie « MOROLA INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie.Me Jacques Lamoureux.Lachine, Que.59533-0 MOROLA INC.Take notice that \"MOROLA INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for the surrender of its charter.Lachine, Que.Me Jacques Lamoureux, Attorney for the company.59533-0 ORMSTOWN WAR MEMORIAL COMMUNITY CENTRE INC.Prenez avis que la corporation « ORMSTOWN WAR MEMORIAL COMMUNITY CENTRE INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la corporation, Me Maurice Malouin, notaire.Valleyfield, Que.59534-0 ORMSTOWN WAR MEMORIAL COMMUNITY CENTRE INC.Take notice that the corporation \"ORMSTOWN WAR MEMORIAL COMMUNITY CENTRE INC.\" will ask the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives peimission to surrender its patent letters.Me Maurice Malouin, notary.Attorney for the corporation.Valleyfield, Que.59534-0 FURNITURE PAVILLON LTD.PAVILLON DU MEUBLE LTEE Avis est par les présentes donné que « FURNITURE PAVILLON LTD.- PAVILLON DU MEUBLE LTEE », une compagnie constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 25e jour du mois de novembre 1974.La secrétaire, 59513-0 Mme Jeanne Yacovelli.FURNITURE PAVILLON LTD.PAVILLON DU MEUBLE LTEE Notice is hereby given that \"FURNITURE PA-VILLON LTD.\u2014 PAVILLON DU MEUBLE LTEE\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city and district of Montreal, Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, Québec, this 25th day of November 1974.Mrs.Jeanne Yacovelu, 59513-0 Secretary.LEONARD LEVITAN & ASSOCIATES LIMITED Avis est par les présentes donné que la compagnie ' LEONARD LEVITAN & ASSOCIATES LIMITED\", corps politique constitué suivant la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 12 décembre 1974.Le secrétaire-trésorier, 59514-0 Jérôme Levitan.LEONARD LEVITAN & ASSOCIATES LIMITED Notice is hereby given that \"LEONARD LEVITAN & ASSOCIATES LIMITED\", a body politic incorporated pursuant to the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter, pursuant to the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 12th of December, 1974.Jérôme Levitan, 59514 Secretary-Treasurer.Mc MAHON DISTRIBUTORS LIMITED Prenez avis que la compagnie « Mc MAHON DISTRIBUTORS LIMITED » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Signé à Toronto, ce 12e jour de décembre 1974.Le secrétaire, 59515-0 E.A.Christie.Mc MAHON DISTRIBUTORS LIMITED Notice is given that \"Mc MAHON DISTRIBU-TORS LIMITED\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Signed at Toronto, this 12th day of December, 1974.E.A.Christie, 59515 Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 197.5, 107' année, îi° 2 105 PAQUET & GAGNON INC.Prenez avis que la compagnie « PAQUET & GAGNON INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Québec, ce 19 décembre 1974.Le procureur de la compagnie, 59516-0 Me Jacques R.Gingras.ROMAR (LAVAL) INC.Avis est donné par les présentes que la compagnie « ROMAR (LAVAL) INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Fait à Montréal, ce 25e jour de novembre 1974.Le procureur de la compagnie, 59517 Isidore Greenbaum.PAQUET & GAGNON INC.Notice is given that \"PAQUET & GAGNON INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Québec, December 19, 1974.Me Jacques R.Gingras, 59516 Attorney for the company.ROMAR (LAVAL) INC.Notice is hereby given that \"ROMAR (LAVAL) INC.\" will make an application to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, this 25th day of November 1974.Isidore Greenbaum, 59517-0 Attorney for the company.WORLD TRAVEL PLAN (CANADA) LTD.Avis est donné que « WORLD TRAVEL PLAN (CANADA) LTD.», une corporation constituée sous la Loi des compagnies et ayant son siège social à Montréal, province de Québec, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 17e jour de décembre 1974.Les procureurs de la compagnie, Duquet, MacKay, Weldon, 59518-0 Bronstetter & Thivierge.WORLD TRAVEL PLAN (CANADA) LTD.Notice is hereby given that \"WORLD TRAVEL PLAN (CANADA) LTD.\".a company incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 17th day of December, 1974.Duquet, MacKay, Weldon, Bronstetter & Thivierge, 59518-0 Attorneys for the company.LAND & CONSTRUCTION COMPANY Avis est donné que « LAND & CONSTRUCTION COMPANY », ayant sa place d'affaires dans le district de Montréal, présentera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives une demande d'abandon de charte.Montréal, ce 23 décembre 1974.Le procureur de la compagnie, 59526-0 Henri Messier, notaire.LAND & CONSTRUCTION COMPANY Notice is given that \"LAND & CONSTRUCTION COMPANY\", having its place of business in the District cf Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, December 23, 1974.Henri Messier, Notary, 59526-0 Attorney for the company.R.B.J.BEEF COUNTER INC.COMPTOIR DU BOEUF R.B.J.INC.Avis est donné que la compagnie « R.B.J.BEEF COUNTER INC.\u2014 COMPTOIR DU BOEUF R.B.J.INC.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Montréal (Québec) s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives en vue d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 19e jour de décembre 1974.Les procureurs de la compagnie, Kaufman, Respitz.59531-0 Sederoff, Shugar & Segal.R.B.J.BEEF COUNTER INC.COMPTOIR DU BOEUF R.B.J.INC.Take notice that \"R.B.J.BEEF COUNTER INC.\u2014 COMPTOIR DU BOEUF R.B.J.INC.\", a company incorporated under the Companies Act, and having its head office at Montreal, Québec, will apply to the Minister of Financial institutions.Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter, under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 19th day of December, 1974.Kaufman, Respitz, Sederoff, Shuoak & Segal, 59531-0 Attorneys for the company. 106 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January H, 1975, Vol.107, No.2 MULTI-INVESTMENTS LTEE Avis est donné que « MULTI-INVESTMENTS LTEE», ayant sa place d'affaires dans le district de Montréal, présentera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives une demande d'abandon de charte.Montréal, ce 23 décembre 1974.Le procureur de la compagnie.59527-0 Henri Messier, notaire, RIVERFARM INVESTMENTS LIMITED Avis est donné que « RIVERFARM INVESTMENTS LIMITED », ayant sa place d'affaires dans le district de Montréal, présentera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives une demande d'abandon de charte.Montréal, ce 23 décembre 1974.Le procureur de la compagnie, 59528-0 Henri Messier, notaire.MULTI-INVESTMENTS LTEE Notice is given that \"MULTI-INVESTMENTS LTEE\", having its place of business in the District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, December 23, 1974.Henri Messier, Notary, 59527-0 Attorney for the company.RIVERFARM INVESTMENTS LIMITED Notice is given that \"RIVERFARM INVESTMENTS LIMITED\", having its place of business in the District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, December 23, 1974.Henri Messier, Notary, 59528-0 Attorney for the company.SODAC LTEE Avis est donné que « SODAC LTEE », ayant sa place d'affaires dans le district de Montréal, présentera au ministre des institutions, financières compagnies et coopératives une demande d'abandon de charte.Montréal, ce 23 décembre 1974.Le procureur de la compagnie, 59529-0 Henri Messier, notaire.SODAC LTEE Notice is given that \"SODAC LTEE\", having its place of business in the district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, compagnies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, December 23, 1974.Henri Messier, Notary, 59529-0 Attorney for the company.BELANGER & GAGNE INC.Prenez avis que la compagnie « BELANGER & GAGNE INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie.Me Albert Labrèche, notaire.Longueuil, Que.59541-o BELANGER & GAGNE INC.Notice is given that the company \"BELANGER & GAGNE INC.\" will ask the Minister of Financial Institutions, Companies and Corporatives for permission to surrender its charter.Me Albert Labrèche, Notary, Attorney for the company.Longueuil, Que.59541-0 BIJOUTERIE PIER AN INC.Prenez avis que la compagnie « BIJOUTERIE PIERAN INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.La procureur de la compagnie.Me Albert Labrèche, notaire.Longueuil, Que.59542-0 BIJOUTERIE PIERAN INC.Notice is given that the companv \"BIJOUTERIE PIERAN INC.\" will ask the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for permission to surrender its charter.Me Albert Labrèche, Notary.Attorney for the company.Longueuil, Que.59542-0 COPEAUX LANDRIENNE INC.Prenez avis que la compagnie « COPEAUX LANDRIENNE INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le 29 novembre 1974.(Sceau) Le secrétaire, Camille La voie.Landrienne, Que.59543-0 COPEAUX LANDRIENNE INC.Notice is given that \"COPEAUX LANDRIENNE INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.November 29, 1974.(Seal) Camille Lavoie, Secretary.Landrienne, Que.59543-q GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n\" 2 107 BECKENEW KNITTING MILLS LIMITED Avis est donné que la compagnie « BECKENEW KNITTING MILLS LIMITED », constituée en vertu de la Loi des compagnies, ayant son siège social à St-Louis-de-Pintendre, district de Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Québec, le 23 décembre 1974.Les procureurs de la compagnie, PlIILIPPON, GARNEAU, Ô9530-o ToURIGNY ET ASSOCIÉS.BECKENEW KNITTING MILLS LIMITED Notice is given that \"BECKENEW KNITTING MILLS LIMITED\", incorporated under the Companies Act, having its head office in St-Louis-de-Pinten-dre, in the district of Québec, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Québec, December 23rd, 1974.Philippok, Garneau, ToURIGNY AND ASSOCIATES, 59530-o Attorneys for the company.DARCON INC.Avis est donné par les présentes que « DARCON INC.», corporation légalement constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu de la Loi des compagnies.Montréal, le 20 décembre 1974.Les procureurs de la compagnie, Guy, Vaillancourt, Bertrand, 59544-0 Bourgeois & Laurent.DARCON INC.Notice is hereby given that \"DARCON INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, December 20, 1974.Guy, Vaillancourt, Bertrand, Bourgeois & Laurent, 59544-0 Attorneys for the company.EQUIPEMENT GENERAL (ST-FELICIEN) LTEE Prenez avis que « EQUIPEMENT GENERAL (ST-FÉLICIEN) LTEE», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 20e jour de décembre 1974.Les procureurs de la compagnie.Desjardins, Duchahme, Desjardins, 59546-0 Tellier, Zigby & Mich au d.GENERAL EQUIPMENT (ST-FELICIEN) LTD.Notice is hereby given that \"GENERAL EQUIPMENT (ST-FÉLICIEN) LTD.\", incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 20th day of December 1974.Desjardins, Ducharme, Desjardins, Tellier, Zigby & Michaud, 59546-o Attorneys for the company.LES FRANCS SOCIETAIRES INC.Avis est donné que la compagnie « LES FRANCS SOCIETAIRES INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.St-Jérôme, le 6 novembre 1974.Le procureur de la compagnie, 59547-0 Me Gaétan Ruel.LES FRANCS SOCIETAIRES INC.Notice is given that the company \"LES FRANCS SOCIETAIRES INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.St.Jérôme, November 6th, 1974.Me Gaétan Ruel, 59547-0 Attorney for the company.HOTEL CHRISTOPHE INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « HOTEL CHRISTOPHE INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Plessisville, le 19 décembre 1974.Le procureur de la compagnie, 59548-0 Jean Têtreault, notaire.HOTEL CHRISTOPHE INC.Notice is hereby given that \"HOTEL CHRISTOPHE INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Plessisville, December 19, 1974.Jean Têtreault, notary, 59548 Attorney for the company. 108 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 ISACELLA INVESTMENTS LTD.Avis est par les présentes donné que « ISACELLA INVESTMENTS LTD.» constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 18e jour de décembre 1974.Les procureurs de la compagnie, 59549-0 Phillips & Vineberg.ISACELLA INVESTMENTS LTD.Notice is hereby given that \"ISACELLA INVESTMENTS LTD.\", incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 18th day of December, 1974.Phillips & Vineberg, 59549-0 Attorneys for the company.LASALLE STEEL INC.Avis est par les présentes donné que « LASALLE STEEL INC.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 24 décembre 1974.Le secrétaire, 59550-o George S.Grostern.LASALLE STEEL INC.Notice is hereby given that \"LASALLE STEEL INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head r.ffice in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 24th day of December, 1974.George S.Grostern, 59550-q Secretary.LE MESSAGER DE LACHINE LTEE Prenez avis que la compagnie « LE MESSAGER DE LACHINE LTEE » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, ce 19e jour de novembre 1974.Le procureur de la compagnie, 59551-0 Maurice Martel, c.r., avocat.LE MESSAGER DE LACHINE LTEE Notice is given that \"LE MESSAGER DE LA-CHINE LTEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, this 19th day of November 1974.Maurice Martel, q.c, lawyer, 59551 Attorney for the company.LE RELAIS ROUTIER (CHARNY) LTEE Prenez avis que « LE RELAIS ROUTIER (CHARNY) LTEE », constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 20e jour de décembre 1974.Les procureurs de la compagnie.Desjardins, Ducharme, Desjardins, 59553-0 Tellier, Zicby & Mi chaud.L.-E.SOUCY INC.Prenez avis que la compagnie « L.-E.SOUCY INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Rimouski, le 30 novembre 1974.Les procureurs de la compagnie, 59554-0 Gagnon & Laliberté.LE RELAIS ROUTIER (CHARNY) LTEE Notice is hereby given that \"LE RELAIS ROUTIER (CHARNY) LTEE\", incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 20th day of December, 1974.Desjardins, Ducharme, Desjardins, Tellier, Zigby & Michaud, 59553-0 Attorneys for the company.L.-E.SOUCY INC.Notice is hereby given that \"L.-E.SOUCY INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Rimouski, November 30, 1974.Gagnon & Laliberté, 59554-o Attorneys for the company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° S 109 DOM REM Y-QUEBEC INC.Prenez avis que la corporation « DOMREMY-QUEBEC INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Fait à Québec, ce 16e jour de décembre 1974.Les procureurs de la corporation, Flynn, Rivard, Jacques, Cimon, 59545-0 Lessard & Lemay.DOMREM Y-QUEBEC INC.Notice is given that \"DOMREMY-QUEBEC INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Given in Québec, this 16th day of December, 1974.Flynn, Rivard, Jacques, Cimon, Lessard & Le.may, 59545 Attorneys for the company.PEINTURE & DECOR (ST.JEAN) LTEE Avis est par les présentes donné que la compagnie « PEINTURE & DECOR (ST.JEAN) LTEE », constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies et ayant son siège -social en la ville de Saint-Jean, Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies et à compter de la date qui sera fixée par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Montréal (Québec), ce 17e jour de décembre 1974.Le président, 59552 Joseph Champagne.PEINTURE & DECOR (ST.JEAN) LTEE Notice is hereby given that \"PEINTURE & DECOR (ST.JEAN) LTEE\", a corporation constituted under Part I of the Companies Act and having its head office in the City of St.Jean, Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the terms of the Companies Act as and from a date to be fixed by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.Montreal, Québec, this 17th day of December, 1974.Joseph Champacne, 59552-0 President.UNITED AUTO PARTS OF VALLEYFIELD LIMITED Prenez avis que « UNITED AUTO PARTS OF VALLEYFIELD LIMITED\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 20e jour de décembre 1974.Les procureurs de la compagnie, Desjardins, Ducharme, Desjardins, 59555-0 Tellier, Zigby & Michaud.UNITED AUTO PARTS OF VALLEYFIELD LIMITED Notice is hereby given that \"UNITED AUTO PARTS OF VALLEYFIELD LIMITED\", incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 20th day of December, 1974.Desjardins, Ducharme, Desjardins, Tellier, Zigby & Michaud, 59555-0 Attorneys for the company.GUY LABRIE LIMITEE Avis est donné que la compagnie « GUY LABRIE LIMITEE » ayant son siège social à Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Québec, ce 20e jour de décembre 1974.Les procureurs de la compagnie, Lafrenière, Maltais, Langlois, 580 est, Grande Allée, Bernier & Vallée.Québec 4.59559-0 GUY LABRIE LIMITED Take notice that \"GUY LABRIE LIMITED\" having its head office in the City of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter.Québec, this 20th day of December 1974.Lafrenière, Maltais, Langlois, Bernier & Vallée, 580 Grande Allée East, Attorneys for the company.Québec 4.59559-0 110 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 APRIL FASHIONS INC.Avis est par les présentes donné que « APRIL FASHIONS INC.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, ce 26e jour de juillet 1974.59572-0 Le secrétaire, Stanley Sklar.APRIL FASHIONS INC.Notice is hereby given that \"APRIL FASHIONS INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, this 26th day of July, 1974.59572-0 Stanley Sklar, Secretary.SUMMF.RLEA INDUSTRIAL PARK LIMITED Prenez avis que « SUMMERLEA INDUSTRIAL PARK LIMITED », une compagnie incorporée en vertu de la loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la |.: [iii \u2014 i.ri d'abandonner sa charte, suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, ce 4e jour de décembre 1974.(Sceau) 59573-0 Le secrétaire de la compagnie, G.J.Cummins.SUMMERLEA INDUSTRIAL PARK LIMITED Notice is herebv given that \"SUMMERLEA INDUSTRIAL PARK LIMITED\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 4th day of December, 1974.(Seal) 59573-0 G.J.Cummins, Secretary of the company.Ministère des Terres et Forêts Cadastre Department of Lands and Forests Cadastre Paroisse de Laprairie de la Madeleine Cadastre officiel de la paroisse de Laprairie de la Madeleine, municipalité de la ville de Brossard, division d'enregistrement de Laprairie.Avis est par la présente donné que le lot 718 est ajouté et qu'une partie des lots 84 à 89 et 91 sont annulées en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 12 décembre 1974.59512-0 Pour le sous-ministre, BenoIt Grimard, a.-o.Paroisse de Laprairie de la Madeleine Cadastre officiel de la paroisse de LapTairie de la Madeleine, municipalité de la ville de Delson, division d'enregistrement de Laprairie.Avis est par la présente donné que les lots 599-2-1, 599-2-3 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 5 décembre 1974.59512-0 Pour le sous-ministre, BenoIt Grimard, a.-g.Parish of Laprairie de la Madeleine Officiai cadastre of the parish of Laprairie de la Madeleine, municipality of the town of Brossard, registration division of Laprairie.Notice is hereby given that lot 718 is added and that a part of lots 84 to 89 and 91 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, December 12, 1974.59512-o BenoIt Grimard, a.-o., For the Deputy Minister.Parish of Laprairie de la Madeleine Official cadastre of the parish of Laprairie de la Madeleine, municipality of the town of Delson, registration division of Laprairie.Notice is hereby given that lots 599-2-1, 599-2-3 arc cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, December 5, 1974.59512-0 BenoIt Grimard, a.-g., For the Deputy Minister. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, u° 2 111 Canton de Stoke Cadastre officiel du canton de Stoke, municipalité de la ville de Bromptonville, division d'enregistrement de Richmond.Avis est par la présente donné que les lots 2-1-27, 2-1-28.2-1-34 à 3-1-37 du rang I sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 4 décembre 1974.Pour le sous-ministre, 59512-0 Norman Lalanne, a.-g.Canton de Stoke Cadastre officiel du canton de Stoke, municipalité du canton de Stoke, division d'enregistrement de Richmond.Avis est par la présente donné que le lot 15A-1 du rang III est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 5 décembre 1974.Pour le sous-ministre, 59512-o Norman Lalanne, a.-g.Township of Stoke Official cadastre of township of Stoke, municipality of the town of Bromptonville, registration division of Richmond.Notice is hereby given that lots 2-1-27, 2-1-28, 2-1-34 to 2-1-37 of range I are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, December 4, 1974.Norman Lalanne, a.-g., 59512-0 For the Deputy Minister.Township of Stoke Official cadastre of township of Stoke, municipality of township of Stoke, registration division of Richmond.Notice is hereby given that lot 15A-1 du rang III is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, December 5, 1974.Norman Lalanne, a.-g., 59512-0 For the Deputy Minister.Régie de l'assurance-maladie du Québec Québec Health Insurance Board Liste par région de noms et adresses d'affaires des professionnels de la santé, qui entendent exercer leur profession en dehors des cadres du régime en qualité de professionnels désengagés ou de professionnels non participants ou qui ont cessé d'exercer leur activité en cette qualité, ainsi que la date à laquelle prend effet leur désengagement ou leur non-participation ou la cessation de celle-ci, publiée conformément à l'article 7.01 des règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie, adoptés par arrêté en conseil No 27, en date du 6 janvier 1971.List compiled on a regional basis, of the names and business addresses of professionals who intend practising their profession outside the scope of the Plan as professionals or who have ceased to practise in this capacity, as well as the date on which their withdrawal or non-participation becomes effective or ceases to become effective, published according to section 7.01 of the regulations respecting the Health Insurance Act adopted by order in council No.27 dated January 6, 1971.Professionnels désengagés Professionals withdrawn Médecins omnipraticiens General Practitioners Date effective du désengagement Effective date of withdrawal Région de Montréal \u2014 Montreal Region Duchesne, Laurent, 75, boul.Dorchester ouest.Bureau 1017, Montréal 128, (Québec) 29-01-71 Région de Québec \u2014 Québec Region Mino.Roland, 2965, 1ère Avenue, Québec 3 (Québec) 30-05-71 Tremblay, Jacques, 590, Saint-Cyrille ouest, Québec 6, (Québec) 23-05-71 Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Chamard, John McLean, 1509 Sherbrooke West, Suite 18A, Montreal 109, (Québec) 16-08-72 Décary, Rémi, 245, Bord du Lac, Dorval (Québec) 01-01-75 Edmison, Ralph Staples.1414.Drummond, Apt.82, Montreal (Québec) H3G 1W1 12-04-74 Lamb, Roland Thomas, 1414 Drummond, suite 1121, Montreal (Québec) H3G 1W1 15-06-74 112 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participation Médecins spécialistes Medical Specialists Région de Montréal \u2014 Montreal Region Almudevar, Manuel, 612 St.John's Road, Suite 114.Pointe-Claire 720, (Québec) Aronovitch, Michael.4119 Sherbrooke Street West.Montreal 215, (Québec) Barker, Charles S., 9 Nelson, Montreal 263.(Québec) Black, Donald Kenneth, Case postale 95, Hudson Heights (Québec) Bossé, Jean, 6555, boul.Gouin ouest, Montréal 389, (Québec) Boulanger, Jean-Baptiste.3610.avenue Atwatcr, Montréal 109, (Québec) Brabander, Joachim, 1390 Sherbrooke Street West, Montreal 109, (Québec) Brow, Georges-Raymond, 1374 Sherbrooke Street West, Suite 7, Montreal 109, (Québec) Browman, Mark, 7841, 2nd Avenue.Montreal 455, (Québec) Butler, Albert A., Medical Arts Bldg., Montreal 109, (Québec) Cantero, Antonio, 1396, Ste-Catherine ouest, Montréal 107, (Québec) Copping, Gordon A., 724 Upper Belmont Avenue.Montreal 217, (Québec) Cordeau.Claire, 1392, Jean-Talon est.app.301.Montréal 329, (Québec) David, Paul P., 8705, rue Barbeau.Montréal 457, (Québec) Dawson, Howard L., 14 Bellevue Avenue, Westmount 217, (Québec) Dumais, Gaston, 12245, Grenct, suite 112, Montréal 390, (Québec) Eakin, W.W\u201e 1538 Sherbrooke Street West.Apartment 704, Montreal 109, (Québec) Fullerton.C.W., 1414 Drummond Street, Montreal 107, (Québec) Gélinas, André.565, Javelin, Dorval 740.(Québec) Genest, Armand, 30, boul.St-Joscph est.Suite 818, Montréal 151, (Québec) Gibbard.Bruce A.4324 Sherbrooke West, suite 48, Montreal (Québec) H3Z 1E1 Gold, Michael M.A., 5785 Côte des Neiges, Apartment 105, Montreal 249, (Québec) Hunt, Brian R., 1538 Sherbrooke West, Apt.622, Montreal 109, (Québec) Johnston, Kenneth B, Main Road.Hudson, Vaudreuil (Québec) Korenbcrg.Lela C.1538 Sherbrooke Street West, Suite 601, Montreal 109, (Québec) Korcnberg, Morton, Medical Arts Bldg.Montreal 109, (Québec) Kravitz, Henry, 4994 Circle Road, Montreal 248.(Québec) I.arivière, Paul.3484, avenue Laval, Montréal 130, (Québec) Legendre, J.Henri, 969.boul.St-Joseph est, appartement 3, Montréal 176, (Québec) Levy, Leonard, 3545, Côte des Neiges, app.118, Montréal 109, (Québec) MacDonald, Allison D.3550.Côte des Neiges, suite 110, Montréal 109, (Québec) MacFarlane, Malcolm R\u201e 1538 Sherbrooke Street West.Apartment 601, Montreal 109.(Québec) Maguirc, J.Gordon, 4485, Sherbrooke ouest, Westmount.Montréal 215, (Québec) Manseau.J.Arthur.960.boul.St-Joscph est, Montréal 176.(Québec) Mason.Edward Halton, 3465, Côte des Neiges, Suite 81.Montreal 109, (Québec) Melhado.Gérald Carlton.900 Sherbrooke Street West.Montreal 110, (Québec) Moll, Albert Edward.3550 Côte des Neiges Road, Suite 570, Montreal 109, (Québec) Montgomery, Lome C, 556 Grosvenor Avenue.Montreal 217.(Québec) Morin.Paul.1280, Girouard, St-Hyacinthc (Québec) Nadler.Norman J., 4141 Sherbrooke ouest app.540, Montréal 215, (Québec) Nairaan, James, 4330, Sherbrooke ouest, Montreal 215.(Québec) Neil.Feeney.27 Holton Avenue.Westmount.Montréal 217 (Québec) Nerman, Yalc, 1115 Sherbrooke West, Suite 1403, Montreal 110, (Québec) Pearson, Georges J.R., 5715, avenue Darlington, Appartement 1, Montréal 251, (Québec) Robert.Paul, 3489 avenue Atwatcr, Appartement 6, Montréal 109, (Québec) Scott.W.Clifford M., 1260 McGregor Avenue, Suite 405, Montreal 109, (Québec) Smith.Clifton Conway, 1538 Sherbrooke Street West, Suite 1020, Montreal 109, (Québec) Smith, Frederick Mclver, 3550, Côte des Neiges, Suite 640.Montréal, (Québec) Stein, Samuel, 1025 Pine Avenue West, Montreal 112, (Québec) Tucker, Elrie Clifford, 1390 Sherbrooke Street West, Apartment 2, Montreal 109, (Quélicc) Wood, David John, 4119 Sherbrooke West, Westmount, Montreal (Québec) 01-12-70 01-12-70 01-12-70 01-12-70 24-09-72 16-04-71 01-12-70 01-12-70 30-07-71 01-12-70 01-12-70 01-12-70 06-01-73 01-12-70 01-12-70 27-03-71 15-01-71 01-12-70 01-12-70 29-01-71 30-06-74 01-12-70 03-01-73 31-12-70 26-08-72 01-12-70 10-06-72 01-12-70 01-12-70 06-04-73 01-12-70 26-08-72 13-02-71 01-12-70 07-01-71 01-01-71 25-04-72 01-12-70 01-12-70 01-12-70 01-03-72 27-04-74 03-01-71 01-12-70 03-02-71 01-12-70 01-12-70 01-12-70 01-07-72 01-12-70 17-05-74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 janvier 1975.107' année, n° 2 113 Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participation Médecins spécialistes Medical Specialists Région de Québec \u2014 Québec Region Lapointe, Donat, 220, Grande-Allée est, app.650, Québec 4, (Québec) Larue, Lucien.964, Casot, Québec 6, (Québec) Parrot, Paul, 1328, avenue des Pins, Sillery, Québec 6, (Québec) Région du Saint-Maurice \u2014 St.Maurice Region Matteau.Jean C, 1661, Royale, Trois-Rivières (Québec) Médecins omnipraticiens General Practitioners Région de Montréal \u2014 Montreal Region Archarabault, Paul A., 2805, Willowdale, Montréal 250.(Québec) Brouille, Raynald, 3775, Saint-Hubert, app.10, Montréal 132, (Québec) Chevrefils, Paul E., 7960, Saint-Denis, Montréal 327, (Québec) Cholettc, Albert M., 5001, Garnier, Montréal 117 (Québec) Gordon, Lionel.6235A, Lennox Avenue, Montreal 251, (Québec) Jacques, Elphège, 190, rue Principale est, Farnham (Québec) Joannette, Jean-Paul, 4930, Mayfair, Montréal 265, (Québec) Mayman, Abe.5845 Côte des Neiges, Suite 690, Montreal 249, (Québec) Scott, Benjamin H., 5146 Westbury Avenue.Montreal 248, (Québec) Vines, Norman M., 1452 Bishop Street, Suite 3, Montreal 107, (Québec) Région de Trois-Rivières \u2014 Trois-Rivières Region Marcotte, Gaston, Case postale 457, Cap-de-la-Madeleine, (Québec) Région de Québec \u2014 Québec Region Leclaire, Yves, 2832, Valcourt, Québec 10, (Québec) Rinfret, Charles G., 1035, boul.Pie XII, Beauport, Québec 5 (Québec) Samson.J.W.14, Parc Samuel Holland, app.1607, Québec 6 (Québec) Région des Cantons de l'Est \u2014 Eastern Townships Region Grainger, Thomas R., Case postale 1500, John Manviile Clinic, Asbestos, Richmond, (Québec) Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Asselin, Charles, 3410, avenue Benny, suite 2A, Montréal 261, (Québec) Asselin, Raymond, 45, rue Saint-Georges, St-Jean, (Québec) J3B 2S2 Baril.Claude.3703, rue Dupuis, Montréal.(Québec) H3T 1E5 Beaulieu, J.Edouard, Case postale 148, Saint-Rémy, Napierville, (Québec) Beaumier, Antoine, 489, Victoria, app.440, St-Lambert (Québec) Beauséjour, Guy, 3766 Queen Mary Road, Montreal (Québec) Bertrand, Jean-Louis, 435, rue Oakville, Dorval (Québec) H9S 2R7 Bieniecki, Irena, 531 Rockland Avenue, Montreal 153, (Québec) Bisaillon, Jean-Jacques, 3333 Queen Marv, app.450, Montréal (Québec) H3V 1A2 Bock, Jean-Guy 3895, Dandurand, Montréal 406 (Québec) HlX 1P5 Bossé, Lucien, 345, avenue Dorval, suite 2, Dorval (Québec) Bourcier, René, 5450, Côte des Neiges, app.600, Montréal 249, (Québec) Bourgoin, Jean-Charles, 1248, rue Lajoie, Montréal 154, (Québec) Bourke, Edward T.18 Thornhill Avenue, Westmount 217, (Québec) Boyles, Williams Howard, 1414 Drummond Street, suite 422, Montreal 107, (Québec) Burns, Frank Léonard, 1414 Drummond Street, Suite 1022, Montreal 107, (Québec) Bushell, Winston C, 1538 Sherbrooke Street West, Suite 1006, Montreal 109, (Québec) Caplan, Herbert, 3535 Queen Mary Road, Suite 315, Montreal 247 (Québec) 13-01-71 26-12-70 01-12-70 02-01-75 01-05-71 02-01-71 13-12-70 01-01-74 15-01-72 01-12-70 01-12-70 17-12-70 22-07-71 01-12-70 21-10-71 01-12-70 13-12-70 27-07-72 01-12-70 17-08-74 17-08-74 17-08-74 30-03-71 26-09-74 17-08-74 17-08-74 02-09-72 17-08-74 31-10-74 17-08-74 17-08-74 15-04-71 09-03-71 02-03-71 13-02-71 10-02-71 11-01-73 114 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 Professionnels non participants Non-parlicipaling professionals Dale effective de non-participation Effective date of non-participation Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Casaubon, Jacques, 2100, Jean-Talon est, Montréal 329, (Québec) Chicoine, Claude R., 1553, rue Viel, Montréal, (Québec) H3M 1G6 Coen, Irving, 43 Donegani Avenue, Apt.2, Pointe-Claire (Québec) Cohen, Robert H., 5153 Coolbrook Avenue, Montreal (Québec) Colle, Albert Joseph, 5253, boul.Décarie, Suite 218, Montréal 248, (Québec) Copelovitch, Bernard, 5845, Côte des Neiges, app.485, Montréal (Québec) H3S 1Z4 Couture, Jean-Paul, 55, avenue de l'Église, app.36, Verdun (Québec) Degrandmont, Claude, 4934, rue Adam, Montréal 404, (Québec) De Grandmont.Madeleine.5870, rue Sherbrooke est, Montréal (Québec) H1N 1B5 De La Fuente, Lucio N., 1000, Jean-Talon est, Montréal (Québec) H3N 1T1 Diner, Murray H., 5757 Decelles, app.336, Montréal (Québec) Dufresne, Roger, 3333 Queen Mary Road, app.440, Montréal (Québec) Dundass, Georges M., 4545, Sherbrooke, Montréal 215, (Québec) Dundass, Roberta Phelps, 4545 Sherbrooke, Montreal 215 (Québec) Elo, James Thomas, 1414 Drummond Street, suite 909, Montreal 107, (Québec) Faith, Robert W., 1538 Sherbrooke Street West, Suite 605, Montreal (Québec) Flam, David J., 4495 Sherbrooke Street West, Montreal 215, (Québec) Fortin, Jean-Marc, 2025, boul.Concorde, Laval (Québec) Franklin, Gérald, 4078 Gage Road, Montreal 218, (Québec) Gagnon, Pierre, 415, boul.St-Joseph est, Montréal (Québec) H2J 1J6 Gendron, Roland.900, Sherbrooke ouest, app.12, Montréal 110.(Québec) Geoffrion, Paul, 1538, rue Sherbrooke ouest.Suite 604, Montréal 609, (Québec) Geoffrion.Roland, 48, Lakeshore, Pointe-Claire (Québec) Griffiths, Victor Bryan, 6600 Trans Canada Highway, Suite 802, Pointe-Claire (Québec) Haie, George H., 465 Victoria Avenue, Apt.131, St-Lambert (Québec) Harvey, Robert F., 474 Strathcona Avenue, Montreal 217 (Québec) Henry, Donald Ward, 227 Kenaston Avenue, Montreal 305, (Québec) Jones, Ronald G., 3550 Côte des Neiges, Apt.320, Montreal (Québec) Kennedy, Ducan J., 6717 Trans Canada Highway, Pointe-Claire 730, (Québec) Kent, Léonard E., 4695 Sherbrooke Street West, Montreal 215 (Québec) Kimura, Akira, 1538 Sherbrooke West, Apt.907, Montréal (Québec) Kleinman, Ezra, 4375 Notre-Dame Blvd., Laval (Québec) Kutzman, Ernest-Abraham, 1538 Sherbrooke Street West, Apt.410, Montreal 109, (Québec) Labelle, Hubert, 666, Sherbrooke ouest, app.501, Montréal 111, (Québec) Labelle, Paul.11271, Henri d'Arles, Montréal 389, (Québec) Lafleur, Roland, 250, avenue Willibrord, Verdun (Québec) Lafortune, Jean-Paul, 5704, Laurendeau, Montréal 205, (Québec) Lajoie, J.Gaston, 5305, Queen Mary Road, Montréal (Québec) Lalanne, Jean-Guy, 719, 1ère Rue, Iberville (Québec) Lamarche, Roger, 6119, Monkland, Montréal (Québec) Laporte, J.Octave Lucien, 8655, Foucher, app.405, Montréal, (Québec) Larue, Charles Arthur, 6746, St-Denis, Montréal 327, (Québec) Lawlor, Robert, 333, chemin Reine-Marie, Montréal 247, (Québec) Lefebvre, Pierre L, 2225, boul.Lapinière, Ville Brossard (Québec) Lefort, Guy, 42, Principale est, Ste-Agathe-des-Monts (Québec) Lefran (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59), 2 \u2014 Autres affaires.[I \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées, i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regu- lation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).rV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). 122 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.S ii.au moins trois membres.\u2014¦ transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(c) Verification of permits.(d) Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.(e) * Special permits.* In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.Catégorie Class Sous-catégories Sub-classes Codes Montreal Quebec Couleurs Numéros de dossiers Colours File numbers Transport public Public transport Transport général General trucking Location Leasing Transport spécialisé Specialized transportation Voyageur MPV QPV Passenger Écolier MPE QPE Student Taxi MPT QPT Taxicab Camionnage régulier MCR QCR Regular trucking Camionnage spécialisé MCS QCS Specialized trucking Transport en vrac MCV QCV Bulk transportation Location ML QL Leasing Maritime MSM QSM Water Aérien MSA QSA Air Ferroviaire MSF QSF Rail Rose Pink Rouge foncé Dark red Jaune orange Orange Orange brûlé Burnt orange Vert pâle Light green Vert foncé Dark green Bleu pâle Light blue Bleu foncé Dark blue Mauve Mauve Brun Brown M 000001 à M 002000 Q 000001 à Q 001000 M 100001 à M 103000 Q 100001 à Q 102000 M 200001 à M 210000 Q 200001 à Q 205000 M 300001 à M 303000 Q 300001 à Q 302000 M 400001 à M 402000 Q 400001 à Q 401000 M 500001 à M 504000 Q 500001 à Q 503000 M 600001 à M 601000 Q 600001 à Q 600500 M 700001 à M 700500 Q 700001 à Q 700500 M 800001 à M 800500 Q 800001 à Q 800500 M 900001 à M 900500 Q 900001 à Q 900500 MPV \u2014 Montréal transport public \u2014 voyageurs / Montreal public transport \u2014 passengers QPV \u2014 Québec transport public \u2014 voyageurs / Québec public transport \u2014 passengers MPE \u2014 Montréal transport public \u2014 écoliers / Montreal public transport \u2014 students QPE \u2014 Québec transport public \u2014 écoliers / Québec public transport \u2014 students MPT \u2014 Montréal transport public \u2014 taxi / Montreal public transport \u2014 taxicab QPT \u2014 Québec transport public \u2014 taxi / Québec public transport \u2014 taxicab MCR \u2014 Montréal transport régulier \u2014 camionnage / Montreal regular transportation \u2014 trucking QCR \u2014 Québec transport régulier \u2014 camionnage / Québec regular transportation \u2014 trucking GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° 2 123 MCS \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 camionnage / Montreal specialized transportation \u2014 trucking QCS \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 camionnage / Québec specialized transportation \u2014 trucking MCV QCV ML QL - Montréal transport en vrac \u2014 camionnage / Montreal bulk transportation \u2014 trucking - Québec transport en vrac \u2014 camionnage / Québec bulk transportation \u2014 trucking \u2022\u2014 Montréal location / Montreal leasing \u2014 Québec location / Québec leasing MSM \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 maritime / Montreal specialized transportation \u2014 water QSM \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 maritime / Québec specialized transportation \u2014 water MSA \u2014 Montréal transport specialise \u2014 aérien / Montreal specialized transportation \u2014 air QSA \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 aérien / Québec specialized transportation \u2014 air MSF \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Montreal specialized transportation \u2014 rail QSF \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Québec specialized transportation \u2014 rail II \u2014 Avis d'introduction de requête: La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues a l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.II \u2014 Notice of submission of application: The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or lo intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.Rôle M-4470 M-501473-D-001 AYLWIN, REAL Nédelec (Témiscamingue) (Que.) Rôle M-4471 M-50118I-D-001 MANSEAU, GÉRARD Rue Si-Jean Wotton (Wolfe) (Que.) Rôle M-4472 M-501471-D-001 GAUTHIER, GERALD 50.rue Québec Rouyn (Que.) Rôle M-4473 M-500994-D-001 DUBÉ, GASTON 15509, Oakwood Pierrefonds (Que.) Rôle M-4474 M-500726-D-001 LECLERC, LIONEL 5848 .3ème Avenue Rosemonl Montréal 405 (Que.) Rôle M-4475 M-50O734-D-0O1 DODGE, GUY 53, Place des Trembles Sorel (Que.) Le requérant, qui possède une attestation M-501473-D-001.demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région No 8.Le requérant, qui possède une attestation M-501181-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région No 5.Le requérant, qui possède une attestation M-501471-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région No 8.Le requérant, qui possède une attestation M-500994-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région No 10.Le requérant, qui possède une attestation M-50O726-D-0O1.demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région No 10.Le requérant, qui possède une attestation M-500734-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région No 6.The applicant, who holds certificate M-501473-D-001, requests a bulk trucking permit.Contractor class, for region No.8.The applicant, who holds certificate M-501181-D-001.requests a bulk trucking permit.Artisan class, for region No.5.The applicant, who holds certificate M-50I471-D-001, requests a bulk trucking permit.Contractor class, for region No.8.The applicant, who holds certificate M-500994-D-00I, requests a bulk trucking permit.Contractor class, for region No.10.The applicant, who holds certificate M-500726-D-001.requests a bulk trucking permit.Artisan class, for region No.10.The applicant, who holds certificate M-50O734-D-O01, requests a bulk trucking permit.Artisan class, for region No.6. 124 Rôle M-4476 M-500718-D-OO! DESLAURIERS, RENÉ 207, boul.Guimond Longueuil (Chambly) (Que.) Rôle M-W77 M-500353-D-002 ST-LAURENT, RENÉ 4575.Delorimier Montréal (Que.) Rôle M-4478 M-500353-D-001 ST-LAURENT, RENÉ 4575.Delorimier Montréal (Que.) Rôle M-4479 M-5OO32I-D-0O1 AUDET, YVES 108.oeme Avenue Ouest La Sarre (Que.) Rôle M^t480 M-500309-D-001 BROCHU, ROGER A.1101.3ème Avenue Est Amos (Que.) Rôle M-4481 M-50O192-D-0O1 MERCIER, ALPHONSE 450.St-Janvier Weedon (Wolfe) (Que.) Rôle M-4482 22682-V-D-l ROULOTTES GAGNON INC.23.rue Forest L'Assomption (Que.) et / and ROULOTTES R.G.GAGNON INC.23, rue Forest L'Assomption (Que.) QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.S Le requérant, qui possède une attestation M-500718-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Anisan.pour la région No 6.Le requérant, qui possède une attestation M-500353-D-002, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région No 10.Le requérant, qui possède une attestation M-50O353-D-0O1, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région No 10.Le requérant, qui possède une attestation M-500321-D-001.demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région No 8.Le requérant, qui possède une attestation M-500309-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région No 8.Le requérant, qui possède une attestation M-500192-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région No 5.Le requérant-vendeur, Roulottes Gagnon Inc., s'adresse à la Commission des transports du Québec dans le but d'obtenir l'autorisation de transférer son permis No 22682-V en faveur du requérant-acquéreur: Roulottes R.G.Gagnon Inc.23, rue Forest L'Assomption (Que.) le tout conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi des transports.Distribution future des actions: Actions ordinaires 75 74 I Louis Gaudette Henri Lafortune Denise Lafortune Ledit permis se lit comme suit: a) Transport restreint - service local - a) L'Assomption et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite ville, pour le transport et le remorquage de roulottes, et maisons mobiles sur leurs roues ou sur les châssis finis ou amovibles fournis ou non par l'expéditeur.b) Transport restreint - longue distance -territoire - b) De tout point à tout autre point situé dans les comtés de L'Assomption, Montcalm, Joliette et Berthier, pour le transport et le remorquage.The applicant, who holds certificate M-500718-D-001.requests a bulk trucking permit.Artisan class, for region No.6.The applicant, who holds certificate M-500353-D-002, requests a bulk trucking permit.Contractor class, for region No.10.The applicant, who holds certificate M-500353-D-001.requests a bulk trucking permit.Contractor class, for region No.10.The applicant, who holds certificate M-500321-D-001.requests a bulk trucking permit, Anisan class, for region No.8.The applicant, who holds certificate M-500309-D-001.requests a bulk trucking permit.Artisan class, for region No.8.The applicant, who holds certificate M-500192-D-001.requests a bulk trucking permit.Contractor class, for region No.5.The applicant-vendor.Roulottes Gagnon Inc.applies to the Québec Transport Commission for authorization to transfer its permit No.22682-V in behalf of the applicant-purchaser: Rouloties R.G.Gagnon Inc.23 Forest Street L'Assomption.P.Q.the foregoing, in conformity with Ihe provisions of section 36 of the Transport Act.Future allotment of shares: Common shares Louis Gaudette: 75 Henri Lafortune: 74 Denise Lafortune: 1 Said permit reads as follows: (a) Restricted trucking - local service - (a) L'Assomption and all points located within a distance of five (5) miles from the limits of said Town, for the transport and haulage of trailers, mobile homes on their own wheels or on finished or removable chassis whether supplied or not by the shipper.(*) Restricted trucking - long distance -territory - (b) From any point to any other point located in the counties of L'Assomption, Montcalm, Joliette and Berthier, for the transport and GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° 2 125 Rôle M-4483 15831-V-D-l-TF LIVRAISON L.GRAVEL DSC.6000.Montée St-François Ville St-Laurent (Que.) Rôle M-4484 23653-V-D-l-TF YVES LEBEAU Rg.Grand Bois St-Grégoire.(Iberville) (Que.) Rôle M-4487 1948-A-D-4 UNCLE HARRY'S BUS SERVICE INC.6060 St-James Street West Montreal (Que.) Rôle M-4488 I948-A-D-5 UNCLE HARRY'S BUS SERVICE INC.6060 St-James Street West Montreal (Que.) de roulottes et maisons mobiles sur leurs roues ou sur les châssis finis ou amovibles fournis ou non par l'expéditeur.Conditions re clauses a et b: a) Le détenteur doit obtenir chaque année de la Commission des transports du Québec, sur paiement d'une somme de $50 l'émission d'une plaque RT amovible à être apposée sur les roulottes durant tout le temps de la livraison et ce, sans préjudice aux autres endroits exigibles en vertu d'autres lois.b) Un registre de tous les véhicules transportés doit être déposé en duplicata à la Commission des transports du Québec chaque semaine.c) Ce registre daté et signé par la détentrice doit comporter les renseignements suivants: 1) date de l'expédition; 2) endroit d'où provient l'équipement; 3) endroit de destination de l'équipement; 4) numéro de la plaque RT amovible fixée à l'équipement; 5) la marque de l'équipement en mentionnant s'il s'agit d'un équipement neuf ou usagé: 6) le numéro de série du connaissement émis.Le requérant demande l'autorisation à la Commission des transports du Québec d'augmenter ses taux de l'ordre de 8%.Demandons la fixation des taux suivants pour l'enlèvement des déchets ou l'enfouissement: Ville d'Iberville et paroisse: $18.00 par famille.Enfouissement-domestique: $3.25 la tonne.Enfouissement commercial: $3.50 la tonne.Service privé: Journalier: $20.00 du voyage.Enfouissement: $4.00 la tonne.- Enfouissement seulement - déchets livrés au dépotoir par le public: $3.50 la tonne.Paroisse d'Iberville - Chalets d'été: $15.00 par famille.La requérante demande à la Commisssion des transports du Québec l'autorisation de donner le service suivant: Service: Transport saisonnier (Catégorie économique) -Description: D'un point à un autre dans le territoire de la Communauté Urbaine de Montréal pour le transport d'étudiants participant à des activités de groupe, soit religieuses, éducatives, culturelles, sportives ou récréatives pour la période s'étendant de novembre 1974 à septembre 1975.La requérante demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation de donner le service suivant: Service: Transport saisonnier (catégorie économique)-Description: Transport d'écoliers de trois (3) à quinze (15) ans de leur résidence sise à Côte St-Luc, Hampstead.Montréal (Notre-Dame-de-Grâce et haulage ot trailers and mobile homes on their wheels or on finished and removable chassis whether supplied or not by Ihe shipper.Conditions re clauses a and b: (a) The holder shall obtain each year, from the Québec Transport Commission, upon payment of the sum of $50.the issue of a removable RT plate to be affixed on the trailers during the time when they are being delivered, the foregoing without prejudice to the other duty exigible by virtue of other legislation.(b) A register of all vehicles carried must be filed in duplicate with the Québec Transport Commission each week.(c) This register, dated and signed by the holder, must contain the following information: (1) Date of shipment; (2) Point of origin of equipment; (3) Point of destination of equipment: (4) Number of removable RT plate affixed to equipment; (5) Make of equipment, with indication as to whether the equipment is new or used: (6) Serial number of bill of lading issued.The applicant requests authorization from the Québec Transport Commission to increase its rates by 8%.We request the fixing of the following rates for the removal or disposal of waste: Town of Iberville and Parish: $18.00 per family.Domestic disposal: $3.25 per ton.Commercial disposal: $3.50 per ton.Private service: Daily: $20.00 per truckload, Disposal: $4.00 per ton.Disposal (burying) only - waste carried to the dump by the public: $3.50 per ton.Parish of Iberville - summer cottages: $15.00 per family.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following service: Service: Seasonal transport (economy class) -Description: From any point to any other point located in the territory of the Montreal Urban Community, for the transport of students participating in group activities of a religious, educational, cultural, sports or recreational nature, during the period extending from November 1974 to September 1975.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following service: Service: Seasonal transport (economy class) -Description: Transport of pupils aged three (3) to fifteen (15) years, from their homes located in Côte-St-Luc, Hampstead.Montreal (Notre-Dame-de- 126 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 Rôle M-4489 M-50O293-D-O0I MORIN, NOËL Sle-Germaine- Boulé (Abiiibi-Esi) (Que.) Rôle M-4490 M-50O5O6-D-OOI LETARTE, CLAUDE Duparquel (Abilibi-Ouesl) (Que.) Rôle 4491 M-SO54I5-D-O01 LAPALME, MICHEL 6323, Saindon Auieuil (Ville de Laval) (Que.) Rôle M-4492 M-500013-D-001 MASUCCI, ELVIO 2166, Cardinal Montréal (Que.) Rôle M-4493 M-501476-D-001 SAVARD, CLAUDE 5.rue Allard Matagami (Que.) Rôle M-4494 M-501475-D-001 ! I Hill II I II ler 17, 18 and 19, 1974.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Devoir » les 24, 26 et 27 août 1974.Rejetée.MS-2019 Cause: MRS-0633 22717-V-S-l ROUSSEL GERVAIS Voiturier-remorqueur / Haulaway operator 659-V SMITH TRANSPORT CO.LIMITED Voiturier roulier / Carrier Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Devoir » les 24, 25, et 26 octobre 1974.Accordée.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on August 24, 26 and 27.1974.Rejected.Du 19 novembre 1974 au 18 novembre 1975 ou décision finale./ From November 19, 1974 to November 18,1976, or final decision.MS-2020-S Cause: MRS-0646 3280-A-S-l A.& Z.AUTOBUS ENRG.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal 2%, nor more than 10%%, payable semiannually on August 15th and February 15th of each, year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, shouh more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from February 15, 1975.Redemption table \u2014 9644,000 \u2014 80 years Date Capital 15 02 1986.10,000 15 02 1987.10,000 15 02 1988.11,000 15 02 1989.12,000 15 02 1990.13,000 15 02 1991.15.000 15 02 1992.16,000 15 02 1993.18,000 15 02 1994 .20,000 15 02 1995 .21,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $21,000, and if greater than the latter latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of February 15, 1995.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipul- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° S 207 dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite confoi mément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $21,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 février de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La municipalité de Chénier s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 février 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement numéro 252 (tel que modifié) \u2014 $644,000 \u2014 aqueduc et égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue à 8 heures du soir, mercredi, le 29 janvier 1975, Salle municipale, 66, rue St-Joseph, Tingwick, comté d'Arthabaska, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Tingwick (Comté d'Arthabaska), ce 27 décembre 1974.Le secrétaire-trésorier, Mme Lucienne F.Nault.Bureau municipal, 50, St-Joseph, Tingwick (Arthabaska), Québec, J0A 1L0, Téléphone : 359-2311, code 819.59524-o Ville de Coaticook Comté de Stanstead Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et pcitant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Roma Fluet, greffier.Hôte] de ville, 150, rue Child, Coaticook, comté de Stanstead, P.Q., jusqu'à 7.30 heures du soir, lundi, le 27 janvier 1975, pour l'achat de $947,500 d'obligations de la ville de Coaticook, comté de Stanstead, datées du 15 février 1975 et remboursables en série du 15 février 1976 au 15 février 1995 inclusivement, avec intérêt à un taux non inféiieui à 9/4%, ni supérieur à 10^%, payable semi-annuelle-meDt les 15 août et 15 février de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortisse- ated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-ycar fixed-term bonds for an amount greater than 321,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on February 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Municipality of ChéDier agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after February 15, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to bylaw number 252 (as amended) \u2014 $644,000 \u2014 waterworks and sewers.Tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held at 8:00 o'clock p.m., on Wednesday, January 29, 1975, at the Municipal Hall, 66 St-Joseph Street, Tingwick, Countv of Arthabaska, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Tingwick (County of Arthabaska), December 27, 1974.Mus.Lucienne F.Nault, Secretary-Treasurer.Municipal Office, 50 St.Joseph, Tingwick (Arthabaska), P.Q.J0A 11.0, Telephone: 359-2311, code 819.59524 Town of Coaticook County of Stanstead Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Roma Fluet, Town Clerk, at the Town Hall, 150 Child Street, Coaticook, County of Stanstead, P.Q., until 7:30 o'clock p.m., on Monday, January 27, 1975, for the purchase of a bond issue of $917,500 for the Town of Coaticook, County of Stanstead, dated February 15, 1975 and redeemable serially from February 15, 1976 to February 15, 1995 inclusive, with interest at a rate of not less than 9} 4%.nor more than 10M%.payable semiannually on August 15th and February 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual 208 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 merits annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 février 1975.Tableau d'amortissement \u2014 $947,500 \u2014 20 ans Date Capital 15 02 1976.$ 30,000 15 02 1977.33,000 15 02 1978.35,000 15 02 1979.38,000 15 02 1980 .49,000 15 02 1981.53,000 15 02 1982 .57,000 15 02 1983.60,000 15 02 1984 .65,000 15 02 1985.70,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $119,500, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances appaiaissant ci-haut, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 février 1995.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication seia faite conformément à la loi.L'échéance du 15 février 1995 au montant de $119,500 comprend un solde de $76,500 renouvelable pour une période additionnelle de 20 ans, et échéant comme suit: redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from February 15, 1975.Redemption table \u2014 $947,500 \u2014 20 years Date Capital 15 02 1986.$ 35,000 15 02 1987 .37,500 15 02 1988 .38,500 15 02 1989 .40,500 15 02 1990 .42,500 15 02 1991.33,000 15 02 1992 .34,500 15 02 1993 .36,500 15 02 1994 .40,000 15 02 1995.119,500 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $119,500, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of February 15, 1995.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of February 15, 1995 in the amount of $119,500 includes a balance of $76,500 renewable for an additional 20-year period, maturing as follows: Date Capital 15 02 1996.$ 1,500 15 02 1997.1,500 15 02 1998.1,500 15 02 1999.1,500 15 02 2000 .2,000 15 02 2001.2,000 15 02 2002 .2,500 15 02 2003 .2,500 15 02 2004 .3,000 15 02 2005 .3,000 Date Capital 15 02 2006.$ 3,500 15 02 2007 .3,500 15 02 2008.4,000 15 02 2009 .4,500 15 02 2010.5,000 15 02 2011.6,000 15 02 2012.6,000 15 02 2013.7,000 15 02 2014.7,500 15 02 2015.8,500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975.107' année, n° 2 209 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.l,e capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 8119,500 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 février de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Coaticook s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 février 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants : 689 \u2014 813.5C0 \u2014 renouvellement d'emprunt; 697 \u2014 $26,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 700 \u2014 849,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 702 \u2014 $21,000 \u2014 renouvellement d'empiunt; 724 \u2014 858,000 \u2014 éclairage; 29-52 \u2014 813,500 \u2014 travaux au parc municipal; 29-7 \u2014 $255,000 \u2014 voirie; 29-8 \u2014 $130,000 \u2014 aqueduc et égouts; 29-9 \u2014 $71,000 \u2014 voirie; 29-10 \u2014 $36,500 \u2014 aqueduc et égouts; 29-11 \u2014 $36,000 \u2014 éclairage; 29-17 \u2014 $14,000 \u2014 aqueduc et égouts; 29-18 \u2014 $7,000 \u2014 aqueduc et égouts; 29-19 \u2014 $93,000 \u2014 aqueduc et égouts; 29-20 \u2014 831.000 \u2014 voirie; 29-21 \u2014 $21,500 \u2014 voirie; 29-22 \u2014 $62,000 \u2014 aqueduc et égouts; 29-26 \u2014 89,500 \u2014 voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue lundi, le 27 janvier 1975, à 7.30 heures du soir, Hôtel de ville, 150 rue Child, Coaticook, comté de Stanstead, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Coaticook (Comté de Stanstead), ce 23 décembre 1974.Le greffier, Roma Fluet.Hôtel de ville, 150, rue Child, Coaticook (Stanstead), Québec, Téléphone: 849-2721, code 819.59523-0 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than 8119,500, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on February 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Coaticook agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after February 15, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 689 \u2014 $13,500 \u2014 loan renewal; 697 \u2014 $26,000 \u2014 loan renewal; 700 \u2014 $49,000 \u2014 loan renewal: 702 \u2014$21,000 \u2014loan renewal; 724 \u2014 $58,000 \u2014 lighting; 29-52 \u2014 $13,500 \u2014 works at the Municipal Park; 29-7 \u2014 $255,000 \u2014 roads; 29-8 \u2014 $130,000 \u2014 waterworks and sewers; 29-9 \u2014 $71,000 \u2014 roads; 29-10 \u2014 $36,500 \u2014 waterworks and sewers; 29-11 \u2014 $36,000 \u2014 lighting; 29-17 \u2014 $14,000 \u2014 waterworks and sewers; 29-18 \u2014 $7,000 \u2014 waterworks and stwers; 29-19 \u2014 $93,000 \u2014 waterworks and sewers; 29-20 \u2014 $31,000 \u2014 roads; 29-21 \u2014 $21,500 \u2014 roads; 29-22 \u2014 $62,000 \u2014 waterworks and sewers; 29-26 \u2014 $9,500 \u2014¦ roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case mav be, to be held on Monday, January 27, 1975, at 7:30\" o'clock p.m., at the Town Hall, 150 Child Street, Coaticook, County of Stanstead, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Coaticook (County of Stanstead), December 23, 1975.Roma Fluet, Town Clerk.Town Hall, 150 Child Street, Coaticook (Stanstead), P.Q.Telephone: 849-2721, code 819.59523 210 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.8 Ventes pour taxes Sales for taxes Municipalité du comté de Brome Municipality of the County of Brome Avis public est, par les présentes, donné par le soussi- Public notice is hereby given by the undersigned, gné, Jean Brunelle, secrétaire-trésorier du conseil mu- Jean Brunelle, Secretary-Treasurer of the Municipal nicipal du comté de Brome, que les terrains ci-après Council of the County of Brome, that the lands hereinaf-mentionnés seront vendus par encan public, à quiconque ter described will be sold, by public auction, to whom-offrira de payer les montants de deniers à prélever, y soever will offer to pay the amount due on such lots compris les frais encourus, à défaut de paiement, avant including costs, the whole in default of previous pay-la vente, des taxes municipales et scolaires et des frais ment of said amounts due, and the whole including encourus pour parvenir à ladite vente; au lieu où le costs incurred, leading to this sale hereby advertised for conseil de comté tient ses séances, à l'édifice du comté municipal and school taxes; at the County House, in the à Knowlton, JEUDI, le TREIZIÈME jour de MARS Village of Knowlton, it being the place where the said prochain, mil neuf cent soixante-quinze, à DIX heures council holds its sessions, the sale to be held on THURS-de l'avant-midi, à savoir: DAY, the THIRTEENTH day of MARCH next, nineteen hundred and seventy-five, at TEN o'clock in the forenoon, to wit: Municipalité Canton de Potton\t\u2014 Municipality Township of Potton\t Noms des propriétaires\tNuméro du cadastre\t \t\tTaxes Names of proprietors\tCadastral n umber\t Barabé, L.et al.\u2022.P.1052 .5 166.14 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du can- Part of said lot of the official plan and book of reference tonde Potton décritesousle No 107181.of the Township of Potton described under No.107181.Bédard, Dale.P.418, P.530.18.62 Parties desdits lots des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lots of the official plan and book of reference canton de Potton décrites sous le No 95603.of the Township of Potton described under No.95603.Booth, Robert.P.1063.18.68 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Potton décrite sous le No 98232.of the Township of Potton described under No.98232.Burke, Terrence.1138-10 .22.23 Cyr, Odilon et Donat Cyr.P.912.114.33 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Potton décrite sous les Nos 92726 et 94042.of the Township of Potton described under Nos.92726 and 94042.Fisher, George.1067-50 .40.28 Galvin, Jack.832.66 35 Houle, Denis Mme / Mrs.856, P.854.14 ! 64 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Potton décrite sous le No 110564.of the Township of Potton described under No.110564.Isherwood John and Mrs.F.M.Whittaker.P.837, 838, P.839, 840, P.841.359.58 Parties desdits lots des plan et livre des renvoi officiels du Parts of said lots of the official plan and book of reference canton de Potton décrites sous les Nos 57306, 57316, 64968.of the Township of Potton described under Nos.57306 57316 64968.Larose, Léo Mme / Mrs.1055, P.299.126.74 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Potton décrite sous le No 111169.of the Township of Potton described under No.111169.M irl in.Lillian Mme/ Mrs.P.715.4 ig Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Potton décrite sous le No 57763.of the Township of Potton described under No.57763.Mitchell, Wm.Mme / Mrs.P.740.59.20 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Potton décrite sousle No 91211.of the Township of Potton described under No.91211. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il janvier 1975, 107' année, n° 2 211 Noms des propriétaires Numéro du cadastre Taxes Names of proprietors Cadastral number McDonald, J.Mme / Mrs.976.$ 186.12 Rocbette, W.P.314.47.48 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Potton décrite sous le No 104861.of the Township of Potton described under No.104861.Ronberg.Malcom.913-11.47.48 St-Onge, Melvina Mme / Mrs.Succ./ Est.P.648.20.37 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Potton décrite sous le No 46237.of the Township of Potton described under No.46237.Schrader, Joan Mile / Miss.P.77.30.40 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Potton décrite sous les Nos 107643 et 107544.of the Township of Potton described under Nos.107543 and 107544.Shaggy Dog Inn.P.835.P.840.710.82 Parties desdits lots des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lots of the official plan and book of reference canton de Potton décrites sous le No 102580.of the Township of Potton described under No.102580.Verrier, William Mme / Mrs.P.754.137.46 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Potton décrite sous le No 109836.of the Township of Potton described under No.109836.Taylor.Stuart.1007 .64.73 Thibault, J.F.Succ./ Est.P.149.65.63 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Potton décrite sous le No 106505.of the Township of Potton described under No.106505.Tougas.André.P.572.P.573.314.44 Parties desdits lots des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lots of the official plan and book of reference canton de Potton décrites sous le No 99289.of the Township of Potton described under No.99289.Municipalité St-Etienne-de-Bolton \u2014 Municipality St-Eticnnc-dc-BoUon Ducree, Pierre.P.507.$ 26.38 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 99102.of the Township of Bolton described under No.99102.O'Hagan, Peter.P.563 .267.68 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 98559.of the Township of Bolton described under No.98559.Municipalité du Village d'Eastman \u2014 Municipality of the Village of Eastman Fortin, René et Fortin Arthur.P.1377.S 46.43 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 106927.of the Township of Bolton described under No.106927.Paige, Frank.P.1016.8.24 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 106927.of the Township of Bolton described under No.106927.Montque Properties Investments Ltd.1271.1280.1370, 1371, P.1372, P.1373.117.49 Parties desdits lots des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lots of the official plan and book of reference canton de Bolton décrites sous le No 102267.of the Township of Bolton described under No.102267.Bullard, Wayne.P-1369.106.98 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 104369.of the Township of Bolton described under No.104369.Brandt, Leslie.P- 1282.120.64 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 87626.of the Township of Bolton described under No.87626. 212 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.8 Noms des propriétaires Numéro du cadastre Taxes Names of proprietors Cadastral number Lacombe, Jeannine.P.1369, 1369-1, P.1369-2, P.1369-29.% 330.66 Parties desdits lots des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lots of the official plan and book of reference canton de Bolton décrites sous le No 96515.of the Township of Bolton described under No.96515.Thériault, Donat.P.1372.348.10 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 101196.of the Township of Bolton described under No.101196.Dompierre, Jacques et Samo Inc.P.1368, 1251.435.1$ Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 106210.of the Township of Bolton described under No.106210.Bourassa, John R.P.1377.105.52 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 107396.of the Township of Bolton described under No.107396.Irwin, Herbert J.P.1098, 1083, P.1084 .786.05' Parties desdits lots des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lots of the official plan and book of reference canton de Bolton décrites sous le No 109176.of the Township of Bolton described under No.109176.Municipalité de Bolton Est \u2014 Municipality of East-Bolton Beauregard, J.Normand.P.960-22.$ 16.14 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 76346.of the Township of Bolton described under No.76346.Bennett, Joanna S.& Salah, Henry.P.1193.20.45 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 102959.of the Township of Bolton described under No.102959.Blanke, Manfred.P.1193, P.1194.6.20 Parties desdits lots des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lots of the official plan and book of reference canton de Bolton décrites sous le No 96136.of the Township of Bolton described under No.96136.Bradley, Allan Mme / Mrs.P.1194.160.26 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 100089.of the Township of Bolton described under No.100089.Carter, Gerald.1289 .24 62 Charron, Richard.P.1179, P.1180.11.78 Parties desdits lots des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lots of the official plan and book of reference canton de Bolton décrites sous le No 101228.of the Township of Bolton described under No.101228.Davis, Ronald.P.777, P.778, P.779, P.780.3.10 Parties desdits lots des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lots of the official plan and book of reference canton de Bolton décrites sous le No 105522.of the Township of Bolton described under No.105522.De Tymowski, J.C.Dr.P.1179.35.28 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 102258.of the Township of Bolton described under No.102258.Gougeon, Adrian.P.1195.211.31 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 102188.of the Township of Bolton described under No.102188.Grifo, Giuseppe G.Mme / Mrs.P.1194.g 20 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 106400.of the Township of Bolton described under No.106400.Labranche, J.Charles.P.654 .996.86 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 87012.of the Township of Bolton described under No.87012.Lachapelle, Aimé.P.1179.15.60 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 95251.of the Township of Bolton described under No.96261. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' aimée, n° 2 213 Noms des propriétaires Numéro du cadastre Names of proprietors Cadastral number Taxes Leimer, Joseph.P.1194.S 140.79 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 99657.of the Township of Bolton described under No.99657.Moran, Kathleen.P.968 .23.54 Royea, Rodney.P.1211.12.00 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 109805.of the Township of Bolton described under No.109805.Stonebanks, Norman F.P.1193.6.20 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 105271.of the Township of Bolton described under No.105271.Municipalité d'Austin \u2014 Municipality of Austin Baillie, David W.P.1622.$ 137.92 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 102883.of the Township of Bolton described under No.102883.Biron, YvanP.P.1479-123.59.97 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi du cadastre du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 102828.of the Township of Bolton described under No.102828.Dionne, Léo.P.1480-13.52.01 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 103044.of the Township of Bolton described under No.103044.Fontaine, Renald et Champlain, Nadeau.1479-154 .70.62 Forbes, Gilles.P.1479-194.42.04 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 103170.of the Township of Bolton described under No.103170.Gerachty, John.P.1477-59.52.01 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 102654.of the Township of Bolton described under No.102654.Heughan, Dorothy Mme / Mrs.1482-6.167.72 Lacerte, Euclide.P.1477-74.59.97 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton da Bolton décrite sous le No 95173.of the Township of Bolton described under No.95173.Lac Webster Dev., G.Godue, C, Nadeau.P.1477, P.1478, P.1478-112, 1477-39, P.1478-9.1,161.16 Lac Webster Dev.Inc.1477-63, P.1477-76, 1477-78.172.03 Lavoie, Philippe Mme / Mrs.P.1480-16.42.04 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 106090.of the Township oi Bolton described under No.106090.Lavoie, Pierre.1477-8.1477-9.86.47 Robitaille, Paul Mme / Mrs.P.1479-225.59.97 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Bolton décrite sous le No 100831.of the Township of Bolton described under No.100831.Municipalité Canton de Sutton \u2014 Municipality Township of Sutton Baceante Invest.Ltd.P.1264.1264-160, 1264-161-3, 1264-161.$ 953.88 Daigle, Yvon.P.461, P.462.35.09 Parties desdits lots des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lots of the official plan and book of reference canton de Sutton décrites sous le No 93924.of the Township of Sutton described under No.93924 Kirby, Norman.1306-4.88.74 Satura, Woolf gang.P- 430.39.71 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du said lot of the official plan and book of reference canton de Sutton décrite sous le No 92692.of the Township of Sutton described under No.92692. 214 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1976, Vol.107, No.2 Noms des propriétaires Numéro du cadastre Taxes Names of proprietors Cadastral number Ramgosch, Jacob.P.542.* 69.72 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Sutton décrite sous le No 92378.of the Township of Sutton described under No.92378.Smith, Cyril.1264-161-2.506.40 Wilson.Roland C.P.1269 .90.18 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Sutton décrite sous le No 92447.of the Township of Sutton described under No.92447.Bendall.Alfred J.386, P.382.115.17 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Sutton décrite sous le No 84543.of the Township of Sutton described under No.84543.Haynes, Gary.P.1358.130.51 Parties dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lot of the official plan and book of reference canton de Sutton décrites sous les Nos 96198 et 107869.of the Township of Sutton described under Nos.96198 and 107869.l'flanzer, Karl.1264-161-1.171.63 La commission scolaire protestante du district de Bedford District of Bedford Protestant Regional School Board Lakeview Estate Inc.P.1133.$1,123.37 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Brome décrite sous le No 102393.of the Township of Brome described under No.102393.Riddel, Estates.481.15.20 Abate.Edigio Mme / Mrs.P.168.213.68 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Brome décrite sous le No 109549.of the Township of Brome described under No.109549.Blake.Peter R.P.1207.334.62 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Brome décrite sous le No 102470.of the Township of Brome described under No.102470.Brack, J.W.W.928-28,928-36.146.64 Charby, Joseph.P.1354.159.31 Parties desdits lots des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lot of the official plan and book of reference canton de Brome décrites sous les Nos 96831 et 88372.of the Township of Brome described under Nos.96831 and 88372.Doucet, André.54, 58.439.28 Dunn, Norma Mme/ Mrs.P.936 .30.69 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Brome décrite sous le No 110316.of the Township of Brome described under No.110316.Ford, R.Mme/Mrs.& Gordon, Mi-Arthur.P.1384-18.73.37 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 106024.of the Township of Brome described under No.106024.Hibbert, Raymond.P.1355.86.37 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 103466.of the Township of Brome described under No.103456.McQuade, Mary Mme I Mrs.P.1148-A-47, P.1148-38-6.485.69 Parties desdits lots des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lots of the official plan and book of reference canton de Brome décrites sous le No 109278.of the Township of Brome described under No.109278.Simpson.Charles.P.936 .21.84 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 84568.of the Township of Brome described under No.84568. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il janvier 1975, 107' année, n° 2 215 Noms des propriétaires Numéro du cadastre Taxes Names of proprietors Cadastral number Williams, Ernest.935-54,935-60.$ 188.65 Williams, Terence.P.936.17.68 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 93227.of the Township of Brome described under No.93227.Aunislne.P.349 .54.20 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 105385.of the Township of Brome described under No.105385.Bromis Inc.103-13, P.103-12, P.103-14, P.103-15.1,104.10 Parties desdits lots des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lots of the official plan and book of reference canton de Brome décrites sous les Nos 107329 et 107330.of the Township of Brome described under Nos.107329 and 107330.Moynan, Wayne.1009.85.62 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Sutton.Of the official plan and book of reference of the Township of Sutton.Commission scolaire Davignon \u2014 Davignon School Board Major Laurent Mines Ltée.P.1252.$2,137.41 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Part of said lot of the official plan and book of reference canton de Sutton décrite sous le No 109532.of the Township of Sutton described under No.109532.Adant, Jean-Louis.P.891.149.75 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Sutton décrite sous le No 104297.of the Township of Sutton described under No.104297.Beauregard, Pierre.1118,1119.1,432.38 Boyer, Françoise Mme I Mrs.P.1341.29.95 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Sutton décrite sous le No 104726.of the Township of Sutton described under No.104726.Hébert, Guy.P.491.gj.jB O'Brien, Richard.1264-77.303.61 Surprenant, Joseph.P.837.52.8 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Sutton décrite sous le No 111451.of the Township of Sutton described under No.111451.Aronovici, Titu.1180-13.43.32 Schneider, Heinrich.P.614.160.25 Raymond, Jules.PP.894 .476.65 Parties dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du Parts of said lot of the official plan and book of reference canton de Sutton décrites sous le No 110209 of the Township of Sutton described under No.110209.Bulka, Prenes.P-173.1,764.75 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 87450.of the Township of Brome described under No.87450.Grow, Haes Marguerite Mme / Mrs.P.816.211.47 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 84999.of the Township of Brome described under No.84999.Rousseau, Jacques.P-255.506.17 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 106732.of the Township of Brome described under No.106732.Siero, Raphael & Mme / Mrs.\"60.378.60 Houle, Alcide Mme / Mrs.P- \"94.101 u0 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Partof said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 89049.of the Township of Brome described under No.89049.Huard, Rosaire.651.753 27 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de East- Of the official plan and book of reference of the Township Farnham.°f East-Farnham. 216 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 Noms des propriétaires Numéro du cadastre Taxes Names of proprietors Cadastral number Lord, Robert, De Cotret, Jacques, René Philippe.345-28.* 95.90 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Brome.Of the official plan and book of reference of the Township of Brome.Labonté.Gaston.127-62.227.57 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Brome.Of the official plan and book of reference of the Townhsip of Brome.Mathieu, Jacques.127-15.47.78 Guérard, Lionel.P.103-26.44.92 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference of de Brome décrite sous le No 109965.the Township of Brome described under No.109965.Therrien, Marcel.127-27.24.09 Therrien.Marcel.127-179-3.31.42 Therrien, Marcel.127-180.82.22 Lacroix, Pierre.324-39.47.35 Lacroix, Pierre.324-49,324-50 .98.82 Raiche, Gilles.127-106.440.46 Raiche, Gilles.Pties 127-107.171.05 Raiche, Gilles.127-108.27.37 Club Sportif Mont Gale Ltée.P.516.84.91 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference of de East-Farnham décrite sous le No 103603.the Township of East-Farnham described under No.103603.Joly, M.et Breton, J.P.P.93.48.58 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference of de Brome décrite sous le No 108920.the Township of Brome described under No.108920.Gosselin, Renaud.432-13.59.58 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de East- Of the official plan and book of reference of the Township of Farnham.East-Farnham.Huard, Rosaire.650.47.25 Auberge des Gais Lurons.513-5, P.513-7, 513-7-6.1,732.53 Auberge des Gais Lurons.513-18.472.48 Aunislnc.350 .51.09 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Brome.Of the official plan and book of reference of the Township of Brome.Drouin, Gérald.P.192 .592.97 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de East- Of the official plan and book of reference of the Township of Farnham.East-Farnham.Dumas, Françoise B.Mme / Mrs.496-31, 496-32 .24.96 Gosselin, Gérard.P.78 .308.24 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference of de East-Farnham décrite sous le No 101881.the Township of East-Farnham described under No.101881.Molenaar, Petrus.30.2,196.35 Shea, John D.P.201 .135.43 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference of de East-Farnham décrite sous le No 110131.the Township of East-Farnham described under No.110131.Péloquin, André.492-30, 493-43.85.12 Zdon, Leopold.P.344.29.24 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference of de East-Farnham décrite sous le No 87600.the Township of East-Farnham described under No.87600.Donné à Knowlton, P.Q., ce troisième jour de janvier, Given at Knowlton, P.Q., this third day of January, mil neuf cent soixante-quinze.nineteen hundred and seventy-five.Le secrétaire-trésorier, Jean Brunelle, 59568-2-2-0 Jean Brunelle.59568-2-2-0 Secretary-Treasurer. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° S 217 Municipalité du comté de St-Jean Avis public est par les présentes donné par Albert O'Cain, secrétaire-trésorier, que les terrains ci-après décrits seront vendus à l'enchère public au lieu où le conseil de comté tient ses sessions, à St-Jean, au numéro 262, de la rue Foch, JEUDI le TREIZIÈME jour de MARS, à DIX heures de l'avant-midi pour taxes municipales et scolaires dues, à moins que ces diverses sommes et les frais encourus ne soient payés avant le jour ci-dessus indiqué.Municipality of the County of St.Johns Public notice is hereby given by Albert O'Cain, Secretary-Treasurer, that the lands hereinafter described will be sold by public auction at the place where the settings of the County Council are held at St-Johns at 262 Foch Street, on THURSDAY, the THIRTEENTH day of MARCH, 1975, at TEN o'clock in the morning for municipal and school taxes dues, unless those various sums and costs incurred be paid before the day above mentioned.\tMunicipalité de St-Blaise \u2014\tMunicipality of St.Blaise\t\t Noms\t\tParoisse\tScol.\t \tLots\tMunie.\t\tTotal Names\t\tParish\tSchool\t Rodrigue Deschênes.Roméo Lefèvre.Donat Osborne.Gérard Robert.Gilles Roy.Gérard Major.Pierre Masse.Maurice Vincelette.P.16.3861, Mackay, Laflèche.16-51, 16-62.791, chemin Richelieu, St-Jean.16-54 .36, Fleury ouest, Montréal.128-11, 129-10.8105, Hochelaga, Montréal.16-61, 16-62.St-Luc, P.Q.12-25 .560, Chomedey, P.Q.P.10.1343, Daniel, ville Jacques-Cartier.P-10.4365, Bordeaux, Montréal.42.75 $\t36.75 S\t79.50 14.81\t17.47\t32.28 7.48\t18.82\t26.30 77.96\t74.60\t152.60 14.81\t\t14.81 6.81\t29.68\t35.49 5.91\t39.04\t44.95 7.76\t37.46\t45.21 Municipalité de Lacadie \u2014 Municipality of Lacadie Elise Boudreau.160-69.Robert Grimard.348-37, 136-137 Mme Robert Grimard.129, chemin Deland, St-Jean, P.Q.514.chemin des Bouleaux, Lacadie.614.chemin des Bouleaux.Lacadie.Leggett Wallace, Succ.P.357.La Curatelle publique, P.358 Montréal.Roger Perrault.160-35.325.chemin Deland, Lacadie.Michel Santerre.160-P.160-151.127.rue des Vétérans, St-Jean.Gabriel Viens.P.152.649.chemin des Carrières, St-Jean.47.05 $\t207\t.34 $\t254.39 41.80\t331\t74\t373.64 4.70\t\t\t4.70 33.90\t\t\t33.90 41.80\t183\t.01\t224.81 44.40\t195\t19\t239.59 \t126\t99\t126.99 Municipalité du village de Lacolle \u2014 Municipality of the Village de Lacolle M.4 Mme Gilles Vachon.P.254.Lacolle.$3,179.17 P.263-2.Robert Copette.P.243-74.%£5\"& Mme Thérèse Ouimet.P.268 .7830.Boyer, Montréal Fabrique Notre-Dame Mont Carmel, P.201.Lacolle.Lacolle.Fernand Tremblay.$ 3,704.20 $ 6,883.37 Donald Boulerice.P.102.623, Beaucage.Ste- P.97 Thérèse-en-Haut 196-11.Lacolle.109.38 66.73 95.00 139.75 92.25 614.18 249.24 407.77 Municipalité de St-Bernard de Lacolle \u2014 Municipality of St.Bernard de Lacolle 201.63 680.91 95.00 389.09 407.77 Mme Lorenzo Francoeur.P.22.St-Bernard.32.67 $ 143.65 $ 176.32 218 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.Z Municipalité de St-Paul-Iles-aux-Noix \u2014 Municipality of St.Paul-Iles-aux-Noix Noms Paroisse Scol.Lots Munie.Total Names Parish School Maurice Bélanger.97-47.Henri Black.102-19.Hector Carreau.P.138-139.Pierre Cyr.P.29.Mme Jean-Louis Denis.P.4.Gérald Ethier.P.30.Donald Guay.P.65-67.Alain Goyette.P.116.Fernand Lacroix.P.116.Pierre Langlois.P.102-97.Mrs.H.Mclnnes.P.4.Mme Armand Rémillard.40-1-2-P.Robert Rivard.P.102-103-104.Noël St-Pierre.P.122.Roland Tremblay.5-315.Omer Wauthier.P.13-14-P.15.60e Avenue.\tS 2.88 $\t32.21 t\t35.09 \t21.43\t51.21\t72.64 \t25.48\t35.41\t60.89 693.Principale.\t44.32\t594.67\t638.99 \t1.68\t23.89\t25.57 717, Principale.\t180.03\t509.55\t689.58 \t5.02\t74.72\t79.74 1315.Principale.\t43.60\t\t43.60 \t33.11\t64.58\t97.69 79e Avenue.\t27.16\t201.85\t229.01 20, 9e Avenue.\t36.32\t80.23\t116.55 837, Principale.\t117.79\t316.80\t434.59 79e Avenue.\t\t393.08\t393.08 1ère Rue.\t\t292.67\t292.67 \t2.64\t17.19\t19.83 \t164.53\t\t164.53 Donné à St-Jean, ce 30e jour de décembre 1974.Le secrétaire, 59576-2-2-0 Albert O'Cain.Cité de Saint-Hyacinthe Avis public est par les présentes donné que l'immeuble ci-dessous décrit, situé dans la cité de Saint-Hyacinthe, sera vendu à l'enchère publique, à la salle du conseil, à l'hôtel de ville, au numéro 750, de l'avenue de I'Hôtel-de-Ville, en les cité et district de Saint-Hyacinthe, MARDI, le VINGT-HUITIÈME jour de JANVIER 1975, à DIX heures a.m., pour satisfaire au paiement des taxes municipales, avec intérêts, plus les frais encourus ou qui pourront être encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.Nom du propriétaire: Réjean (alias Regent) Turcotte, comme grevé de la substitution créée par le testament de feu Jacques Turcotte, en son vivant rentier des cité et district de Saint-Hyacinthe.Description: un emplacement situé en la cité de Saint-Hyacinthe, à l'angle des rues Marguerite-Bourgeois et Saint-Simon, faisant partie du lot numéro deux cent soixante-sept (P.267) des plan et livre de renvoi officiels de ladite cité, de la contenance de soixante pieds sur la rue Saint-Simon, sur soixante-dix pieds de profondeur, mesure anglaise, renfermé dans les bornes suivantes: en front, la rue Saint-Simon, en profondeur, le lot No 275, d'un côté, la rue Marguerite-Bourgeois, telle qu'élargie depuis le 20 mai 1903, et telle que l'indique une borne plantée par l'arpenteur dans l'automne de 1903; et de l'autre côté, par le lot 267-1 ; avec les bâtisses y construites portant les numéros civiques 305, 307 et 309 de l'avenue Saint-Simon et dépendances y érigées.Avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble.Saint-Hyacinthe, ce 19e jour de décembre 1974.Given at St.Johns, this 30th day of December 1974.Albert O'Cain, 59576-2-2-0 Secretary.City of St.Hyacinthe Public notice is hereby given that the hereinafter described immovable property will be sold by public auction in the Council Room of City Hall, located at 750 Hotel-de-Ville Avenue, in the City and District of St.Hyacinthe, on TUESDAY, the TWENTY-EIGHTH day of JANUARY, 1975, at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy to the payment of municipal taxes, with interest and costs incurred thereon, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale.Name of the proprietor: Réjean (alias Regent) Turcotte, as institute of the substitution created by the last will and testament of the late Jacques Turcotte, in his life-time of the City and District of St.Hyacinthe.Description: an emplacement situated in the City of St.Hyacinthe, at the corner of Marguerite-Bourgeois and St-Simon streets, being part of lot number two hundred and sixty-seven (Pt.267) on the official plan and book of reference of the City of St.Hyacinthe, measuring sixty feet on St-Simon Avenue by seventy feet in depth, English measures; bounded as follows: to the front, by St-Simon Avenue; to its depth, by lot No.275; to one side by Marguerite-Bourgeois Street, at it is since it was widened on May 20, 1903, as it is indicated by a landmark which was set by land surveyor, on the fall of 1903, and to the other side, by lot No.267-1; with buildings thereon erected, bearing civic numbers 305, 307 and 309 of St-Simon Avenue and dependencies thereto attached.With all active and passive, apparent or occult servitudes attached to the said property.St.Hyacinthe, this 19th day of December, 1974.59502-l-2-o Le greffier, Richard Bousquet.59502-l-2-o Richard Bousquet, City Clerk. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U janvier 1975, 107' année, n° 2 219 Municipalité du comté de Compton Avis public est par les présentes donné par Marc Rousseau, secrétaire-trésorier de la municipalité du comté de Compton, que les propriétés ci-après décrites seront vendues à l'enchère publique au bureau du comté de Compton, à Cookshiie, JEUDI, le TREIZIÈME jour de MARS 1975, à DIX heures de l'avant-midi, pour les taxes municipales, scolaires et autres charges dues aux municipalités ci-après mentionnées, sur les divers lots ou morceaux de terrain ci-après désignés, à moins qu'elles ne soient payées avant la vente, avec les frais.Municipality of the County of Compton Public notice is hereby given by Marc Rousseau, Secretary-Treasurer of the Municipality of the County of Compton, that the properties hereinafter described shall be sold by public auction at the office of the County of Compton, at Cooksliire, THURSDAY, the THIRTEENTH day of MARCH 1975, at TEN o'clock in the forenoon, for the municipal and school taxes and othei charges due to the hereinafter municipalities upon the several lots or parcels of land hereinafter described unless the same be paid, with costs before the sale.Municipalité de Bury \u2014 Municipality of Bury Propriétaires Owners\tNo des lots Lots No.\tRang Range\tAcres\tTaxes munie.Munie.Taxes\tTaxes scol.School taxes\tTotal \t11-10.\t6.10.\t\tS 232.10 55.18\tS 625.13 122.19\t$ 857.33 177.37 \t27d.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Canton de Ditton \u2014 Township of Ditton\t\t\t\t\t\t \t63, 64.\t2.3.2.3.4.6.\t\t8 55.43 6.30 9.14 7.55 20.81 9.41\t* 60.47\t1 55.43 6,30 69.61 7.55 20.81 9.41 Wilfrid Grégoire Inc.\tP.105.\t\t\t\t\t \tP.75.\t\t\t\t\t \tP.92.\t\t\t\t\t Elkthal, Arthur R.\t153, 154.\t\t\t\t\t Demers, Léo et Richard, Noël.\tP.454.\t\t\t\t\t Canton d'Eaton \u2014 Township of Eaten\t\t\t\t\t\t Chalet des Erables Inc.Dept.des Anciens Combattants et\t16a, P.16ft.P.20.\t4____ 5.\t147.197.\tS 267.94 297.70\tt 486.80 604.06\t$ 754.74 901.76 Ville d'East Angus \u2014 Town of East Angus \t14-1-22.\t\t\tS 413.31 647.88 26.32 83.64\tS 299.83 498.85 26.78 85.73\tS 713.14 1,146.73 53.10 169.37 \tP.15a-22.\t\t\t\t\t \t12-12-31.\t\t\t\t\t \t14-35-110-77, 78, 79.14-35-110-83.84\t\t\t\t\t Canton de Hampden \u2014 Township of Hampden\t\t\t\t\t\t \t\t2____ 3.\t100.\tS 28.00 57.21\tS 21.44 58.87\t* 49.44 116.08 \tP.179.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Canton de Hereford \u2014 Township of Hereford\t\t\t\t\t\t Alfred Bouchard & Fils.Att: M.Georges Bouchard\tP.6a, P.6a, P.66.\t1.\t2^.\tS 322.50\t\t8 322.50 220 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 Canton de Newport \u2014 Township of Newport Propriétaires Owners\tNo des lots Lots No.\tRang Range\tAcres\tTaxes munie.M unie.Taxes\tTaxes scol.School taxes\tTotal \tP.19k.\t5.11.\t14.\tS 0.32 1.02\tS 0.44 1.31\tS 0.76 2.33 \tP.10b.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Canton de Westbury \u2014 Township of Westbury\t\t\t\t\t\t Bell Russel .\tP.Ilk.\t1____ 1____ 3.\t\tS 76.06 28.49\tS 61.52\t$ 76.06 28.49 61.52 \tP.115.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Donné à Cookshire, ce 2e jour de janvier 1975.Given at Cookshire, this 2nd day of January 1975.Le secrétaire-trésorier, Marc Rousseau, 59563-2-2-0 Marc Rousseau.59563-2-2-0 Secretary-Treasurer.Cité il' Aliii:i Avis public est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la Cité, que les propriétés ci-après décrites seiont vendues à l'enchère publique, au lieu ordinaire des assemblées du conseil, en l'hôtel de ville de.la Cité d'Alma, LUNDI le DIXIÈME jour de FÉVRIER 1975, à DIX heures, pour payer les taxes municipales et scolaires avec les intérêts et les frais, plus les frais encourus subséquemment, à moins que lesdites taxes, les intérêts et les frais ne soient payés avant la vente.City of Alma Public notice is hereby given by the undersigned.City Clerk, that the properties hereafter described will be sold by public auction at the ordinary place of the meetings of the municipal council of the City of Alma, at the Alma city hall, on MONDAY, the TENTH day of FEBRUARY 1975, at TEN o'clock, for the payment of municipal school taxes with the interest and costs, plus the costs subsequently incurred, unless the said taxes, interest and costs are paid before the sale.Taxes Taxes Noms et adresses des propriétaires Désignation cadastrale munie.scol.Total Names and addresses of proprietors Cadastral designation Munie.Scol.taxes taxes Beau Lac Construction Ltée, 895 o.Boulanger, Aima.Beau Lac Construction Ltée, 895 o.boulanger, Aima.Beau Lac Construction Ltée, 895 o.Boulanger, Aima.Blackburn, Mme Léon-Marc.65 o.St-Bernard, Aima.Brassard, Arthur, 222 e.Sacré-Coeur, Aima Deschesnes.Léonce, 195 o.Bourgeoys, Aima.Fédération Coop.Habitat, 2030 Père Lelièvre, Québec.Forget Marcel, 1045 o., Grimard, Aima.Gagnon René, 1800 o.Scott, Aima.Caron Jean-Guy, 114 Lapointe, Kénogami.Immeubles Lavoie Inc., 145 boul.Dequen, Aima.6-1-6-1 - Desmeules 4-169, Rang I, Delisle.6-1-6-2 - Bourgeois 3b-159 & 4-167, Rang I, Delisle 6-1-6-14 - Desmeules 4-168, Rangl, Delisle 8-2-5-3 - St-Bernard P.1-A, la-3-7, la-3-8, la-4-6, la-4-7, Rang I, Delisle.3-8-1-3-Sacré-Coeur, P.2-A, Rang Saguenay, Labarre 7-4-5-7 Bourgeoys, l-A-21, Rang I, LA.Delisle.2-5-6-13 des Hydrangers 15a-35, Rang VIII, Signay.4-1-5-14 Scott O, P.17-A, Rang IX, Signay.4-3-5-2-1 - Scott.P.20B, P.20c et P.21 Rang IX, Signay.8-1-1-5-655 0.Price.P.3b-133 Rang 1 Delisle.1-5-8-1 DeQuen 3-b-l & P.3-b-2 Rang 1.Delisle.5, 13\t08\t$ 188\t52\t8 202.20 12\t42\t188\t52\t200.94 13\t70\t188\t52\t202.22 163\t40\t377\t99\t541.39 147\t17\t291\t58\t438.76 206\t22\t1,296\t99\t1,503.21 4\t36\t\t\t4.36 987\t28\t1,011\t21\t1,998.49 66\t76\t\t\t66.76 102\t69\t291\t68\t394.27 266\t79\t4,986\t56\t10.253.36 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° S 221 Noms et adresses des propriétaires Names and addresses of proprietors Tremblay Fernando, 275 o.Scott, Aima.Tremblay Raoul.81 o.Des Cyprès, Aima.Tremblay Raoul, 81 o.Des Cyprès.Aima.Désignation cadastrale Cadastral designation 3-1-3-14 - 275 Scott.13A-135 Rg.IX Signay.6-1-3-13 - 250 Boul.Dequen - 3b-63-Rang 1, Delisle.6-1-3-14 - 725 St-Sacrement.3b-65 Rg.1 - Delisle.Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.Scol.taxes Total $ 202.56 $ 379.67 $ 583.23 853.30 1,217.59 2,070.89 46.87 77.52 124.39 Donné à Aima, ce 31e jour de décembre 1974.Le greffier, 59562-2-2-0 Raymond Fortin.Given in Alma, this 31st day of December 1974.Raymond Fortin, 59562-2-2-0 City Clerk.Municipalité du comté de St-Hyacinthe Avis public est, par les présentes donné, par le soussigné J.-Jacques Giasson, secrétaire-trésorier de la corporation municipale du comté de St-Hyacinthe, que les immeubles suivants ci-après décrits seront vendus à l'enchère publique, à la salle du conseil au Palais de Justice, en la cité de St-Hyacinthe, JEUDI, le TREIZIÈME jour de MARS 1975, à DIX heures de l'avant-midi pour satisfaire au paiement des taxes et autres redevances dues aux municipalités mentionnées ci-dessous, plus les frais subséquemment encourues, à moins que ces taxes, redevances et frais ne soient payés avant la vente : Municipality of the County of St.Hyacinthe Public notice is hereby given by the undersigned J.-Jacques Giasson, Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of the County of St-Hyacinthe, that the following immoveables hereinafter mentionned will be sold by public auction, in the hall of the county council, at the Court House, on THURSDAY, the THIRTEENTH day of MARCH 1975, at TEN o'clock in the forenoon, for the payment of taxes and other dues owing to the municipalities hereinafter mentioned, plus the costs incurred, unless these taxes, dues and costs have been paid prior to the date of the sale: La corporation municipale de la paroisse Ste-Marie-Madeleine Municipal Corporation of Parish Ste-Marie-Madeleine \t\tTaxes\tTaxes\tInt.et\t Propriétaire\tNo du cadastre\tmunie.\tscol.\tfrais\tTotal Owner\tNo.of cadastre\tMunie, taxes\tSchool taxes\tInt.and costs\t Lussier Serge.C.P.215, Roxton Ponds,\t96-44.\t\t$ 90.86\tS 9.05\t$ 99.91 Cté Shefford.\t96-47.\t\t23.54\t2.32\t25.86 \t96-48.\t\t23.54\t2.32\t25.86 \t96-49.\t\t21.19\t2.13\t23.32 Lajoie, Robert et Lussier, Serge, a/s Serge\t96-44.\tS 23.66\t\t2.33\t25.99 \t96-47\t\t\t\t \t96-48 96-49 289.\t\t\t\t Patenaude, Rita L., 160, Lafrance, St-Basile-\t\t\t676.63\t42.37\t619.00 le-Grand.\t\t\t\t\t La corporation municipale du village Ste-Marie-Madeleine Municipal Corporation of the Village of Ste-Marie-Madeleine Bédard André, 500.Laurier, Ste-Madeleine.3903 S 395.84 S 39.80 $ 435.64 Donné à La Présentation, ce 2e jour de janvier 1975.Given in La Présentation, this 2nd day of January 1975.J.-Jacques Giasson, 59569-2-2-0 Le secrétaire-trésorier, J.-Jacques Giasson.59569-2-2-0 Secretary-Treasurer. 222 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 La commission scolaire Mont-Fort Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Pierre Lépine, ca.directeur général de la commission scolaire Mont-Fort, dans le comté de Chambly, que les immeubles ci-après décrits seront vendus à l'enchère publique, en la ville de St-Bruno de Montarville, à 1125-1139 rue Cadieux, le TREIZIÈME jour du mois de MARS 1975, à DIX heures de l'avant-midi, pour le paiement des cotisations municipales et scolaires et autres charges dues aux municipalités ci-après mentionnées, si ces diverses cotisations ne sont pas payées avec les frais et intérêts avant le jour fixé pour la vente.La commission scolaire Mont-Fort Public notice is hereby given by the undersigned, Pierre Lépine, c.a.director general of La Commission Scolaire Mont-Fort, in the County of Chambly, that on the THIRTEENTH day of MARCH 1975.shall be sold by public auction, at TEN o'clock in the forenoon, at 1125-1139 Cadieux Street, in the Town of St.Bruno de Montarville the thereafter described immovables for the payment of municipal and school taxes and other charges due to the hereafter mentioned municipalities, unless same are paid with costs and interest before the day mentioned for the sale.Ville de Carignan, cadastre officiel de la paroisse St-Joseph de Chambly Town of Carignan.official cadastre of the Parish of St.Joseph of Chambly Propriétaires Owners Cadastre Taxes\tTaxes\t scol.\tscol.\tTaxes cath.\tprot.\tmunie.Cath.\tProt.\tMun.school\tschool\ttaxes taxes\ttaxes\t Total Electra Park Development .P.127 .Une terre, située en la municipalité de Carignan, dans le comté de Chambly.sise dans la concession ouest du Bassin de Chambly; contenant en superficie cent soixante-cinq arpents, plus ou moins, sans garantie de la contenance composée: De cette partie non subdivisée du lot originaire cent vingt-sept (P.127) du cadastre officiel de la paroisse de St-Joseph de Chambly.division d'enregistrement de Chambly, el comprise dans les limites suivantes: en front, vers l'est, le sud et le sud-est le chemin de front longeant la rivière Montréal; en arrière, vers l'ouest, la ligne limitative des paroisses de St-Joseph de Chambly et de St-Huben, comté de Chambly; du côté nord, le lot numéro cent vingt-six (126), et du côté sud, le lot numéro cent vingt-huit el ses subdivisions; sauf et â distraire; les parties décrites dans l'acte enregistré sous le numéro 185548 du 18 juin 1959 ainsi que des subdivisions enregistrées à la suite de cet acte.Murphy.Preston.127-2228 Murphy, Preston.127-2229 Spencer.Kenneth .127-2485 .Bouchard, Donald (Syndic) .127-2759 128-2578 Desautels, Succ.Mme Adrien.P.128 .365.59 $ 54.00 419.59 Le lot numéro P.128 borné à l'ouest par le chemin de front de la rive nord de la Rivière Montréal; à l'est par ladite rivière; au nord par le lot numéro 127 et au sud par une ligne imaginaire (droite) partant à angle droit, près du chemin public à l'extrémité nord du iot triangulaire numéro 128-1 pour se diriger dans une direction ouest-est depuis ledit chemin à la rivière.Tous du cadastre de la paroisse St-Joseph de Chambly.Picciano, Lorenzo.128-374, 375 .129-303.304 Lavigne, Bruno.128-535, 536 .Opdekamp, Charles .128-1931 à/to 1935 incl.A land situated in the Municipality of Carignan.in the County of Chambly, located in the Western concession of the Basin of Chambly; of a total surface area of 165 acres, more or less without guarantee of the area as follows: The non subdivised part of original lot Pi.127 of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly of the Registry Division of Chambly and included in the following limits: In front, towards east, south and southeast, the front road along Montreal River; to the rear towards west, the limit line of the Parishes of St-Joseph of Chambly and of St-Hubert, County of Chambly; on the north side, the lot No.126 and on the south side, the lot No.128 and its subdivisions; except and to exclude: the parts described in the deed of sale registered under No.185548 on the 18th day of June 1959 also the subdivisions registered subsequent to this deed.21.74 21.74 15.67 26.37 3.56 7.05 21.74 21.74 19.23 33.42 .91.53 91.53 Lot No.Pt.128 bounded to the west by the front road of the north shore of the Montreal River; lo the east, by the said river; to the north, by lot No.127 and to the south by a (straight) imaginary line, at right angle near Ihe public road to the north extremity of the triangular lot No.P-128-1 and towards a west-east direction from the river road.All of the cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly.20.48 14.82 35.79 5.92 2.76 2.35 26.40 17.58 38.14 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il janvier 1975.107' année.n° 2 223 \t\tTaxes\tTaxes\t \t\tscol.\tscol.\tTaxes Propriétaires\t\tcath.\tprot.\tmunie.\tCadastre\t\t\t Owners\t\tCath.\tProt.\tM un.\t\tschool\tschool\ttaxes \t\ttaxes\ttaxes\t 128-2572 .\t8.08\t1.13\t 129-192, 193 .\t14.82\t\t2.76 129-535, 536 .\t20.49\t\t2.97 130-58 à / to 61 incl .\t37.44\t\t 131-7 à / to 10 incl.\t\t\t 131-492, 493 .\t16.03\t\t 132-116 .\t3.83\t\t0.85 132-683 à / to\t42.68\t\t6.28 688 incl.\t\t\t P.242 .\t509.95\t\t Une terre située en la paroisse de St-Joseph de Chambly.dans le district de Montréal, connue et désignée comme étant une partie du lot numéro deux cent quarante-deux du cadastre officiel de ladite paroisse de St-Joseph de Chambly, contenant environ soixante-mx-huit arpents en superficie, bornée à l'ouest par Albert Dubois, Alexandre Perrier, Joseph Trudeau, Thomas Lamarre, Elzéor De-neault, Médard Marcil, François Toupin ou les représentants de chacun d'eux, au nord par un nommé Blanchette, à l'est par Arthur Deneault et au sud par les représentants d'Alphonse Lague, la terre décrite dans l'acte No 79244, soit le lot No 78.et Edmond Bros-seau.avec les bâtisses dessus construites.Terrasse Richelieu Inc.263-P.268 .Un terrain connu et désigné sous le numéro deux cent soixante-huit de la subdivision du lot originaire deux cent soixante-trois (263-268) du cadastre officiel de la paroisse St-Joseph de Chambly.Acte No 280946, Me L.H.Wisse 7/3/67.A distraire l'expropriation enregistrée sous le No 315717.Terrasse Richelieu Inc.263-P.269 .Un terrain connu et désigné sous le numéro deux cent soixante-neuf de la subdivision du lot originaire deux cent soixante-trois (263-269) du cadastre officiel de la paroisse St-Joseph de Chambly.Acte Ne280946, Me L.H.Wisse 7/3/67.A distraire l'expropriation enregistrée sous le No 315717.Terrasse Richelieu Inc.263-P.270 .263-P.334 263-P.341 Certains lots connus et désignés sous les numéros deux cent soixante-dix, trois cent trente-quatre et trois cent quarante et un de la subdivision du lot originaire deux cent soixante-trois (263rP.270) (263-P.334) (263-P.341) du cadastre officiel de la paroisse St-Joseph de Chambly, Acte No 217457.Me I.Rapp 27/6/62.A distraire de ces lots l'expropriation enregistrée sous le No 315718.Terrasse Richelieu Inc.263-P.342 .Un certain lot connu et désigné sous le numéro trois cent quarante-deux de la subdivision du lot originaire deux cent soixante-trois (263-P.342) du cadastre officiel de la paroisse St-Joseph de Chambly.Acte No 217457.Me.I.Rapp 27/6/62.A distraire de ce lot l'expropriation enregistrée sous le No 315718.Terrasse Richelieu Inc.263-P.348 .Un certain lot connu et désigné sous le numéro trois cent quarante-huit de la subdivision du lot originaire deux cent soixante-trois (263-P.348) du cadastre officiel de la paroisse St-Joseph de Chambly.Acte No 217457, Me I.Rapp 27/6/62.A distraire de ce lot l'expropriation enregistrée sous le No 315718.9.21 17.58 23.46 37.44 16.03 4.68 48.96 509.95 A land located in the Parish St-Joseph of Chambly.in the District of Montreal, known and designated as being part of lot (242) of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly.approximatively seventy-eight (78) acres in surface area, bounded to Ihe west by Albert Dubois.Alexander Perrier.Joseph Trudeau, Thomas Lamarre, Elzéor Deneault, Médard Marcil, Francois Toupin or their representatives; to the north by a named Blanchette; to the east by Arthur Deneault and to the south by the representatives of Alphonse Lague.the land described in the deed No.79244 namely the lot No.78 and Edmond Brosseau.with the buildings erected thereon.7.01 8.86 130.70 .114.83 A lot known and designated under No.263-268 of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly.Deed No.280946, Notary L.H.Wisse 3/7/67.Excluding the expropriation registered under No.315717.65.43 2.94 4.94 73.31 A lot known and designated under No.263-269 of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly.Deed No.280946.Notary L.H.Wisse 3/7/67.Excluding the expropriation registered under No.315717.35.41 4.59 40.00 Certain lots known and designated under Nos.263-P.270, 263-P.334 and 263-P.341 of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly.Deed No.217457, Notary I.Rapp 6/27/62.Excluding the expropriation registered under No.315718.71.51 3.49 4.94 79.94 A certain lot known and designated under No.263-P.342 of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly.Deed No.217457.Notary 1.Rapp 6/27/62.Excluding Ihe expropriation registered under No.315718.52.94 1.36 2.69 56.99 A certain lot known and designated under No.263-P.348 of the official cadastre of Ihe Parish of St-Joseph of Chambly.Deed No.217457, Notary I.Rapp 6/27/62.Excluding the expropriation registered under No.315718. 224 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 \t\tTaxes\tTaxes\t \t\tscol.\tscol.\tTaxes Propriétaires\tCadastre\tcath.\tprot.\tmunie.Owners\t\tCath.\tProt.\tMun.\t\tschool\tschool\ttaxes \t\ttaxes\ttaxes\t Galarneau.Gaston.353-353 .Galameau, Gaston.353, 354, P.353 Un immeuble sis en la paroisse de St-Joseph de Chambly, ayant front sur la rue Des Tulipes, et composé: a) Des lots connus et désignés au cadastre officiel de la paroisse St-Joseph de Chambly sous les numéros trois cent cinquante-trois et trois cenl cinquante-quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro trois cent cinquante-trois (353-353, 354); b) De tout le terrain qui se trouve en arrière du lot 353-353 ci-dessus décrit et compris entre ce dernier et la rivière Montréal, faisant partie du lot originaire numéro trois cent cinquante-trois (P.353) auxdits plan et livre de renvoi, borné de chaque côté par le prolongement en ligne droite des lignes latérales du lot 353-353 et à chacune de ses extrémités par la rivière Montréal et ledit lot 353-353.Avec bâtisses y érigées, notamment une maison portant le numéro 1912 de ladite rue Des Tulipes, circonstances et dépendances et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, légales et constituées attachées audit immeuble.Goyer.Charles-Emile.353-P.385 .Le lot 353-P.385 du cadastre officiel de la paroisse St-Joseph de Chambly tel que décrit dans l'acte de vente de Me Léo Lareau enregistré sous le numéro 187035 à distraire la partie vendue sous le numéro 330457.Côté.André.353-1253 .Uvesque.Oscar.357-107.108 .Nadeau, Raymond.357-165.166 .Bessette.Mme Claire.357-185.P.186 a) Un terrain vacant, situé en la municipalité de Chambly.comté de Chambly, dans l'Ile Demers; connu et désigné sous le numéro cent quatre-vingt-cinq de la subdivision officielle du lot originaire trois cent cinquante-sept (357-185) du cadastre officiel de la paroisse St-Joseph de Chambly; circonstances et dépendances.Ce terrain mesure cinquante pieds de largeur par cent pieds de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins.Acte de vente 377980, Me Léo Lareau 19/3/73.b) La demi-partie nord-ouest du lot No cent quatre-vingt-six de la subdivision du lot originaire trois cent cinquante-sept (357-P.186) du cadastre officiel de la paroisse St-Joseph de Chambly.Acte de vente 377980, Me Léo Lareau 19/3/73.Le lot 357-P.186 mesurant en totalité 50' de largeur par 100' de profondeur avant subdivision.316.57 316.57 .74.23 74.23 A property located on Des Tulipes Street.Town of Carignan in the Parish of St-Joseph of Chambly as follows: (a) Lots known and designated to the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly under Nos.353-353, 354.(b) All the land located at the rear of lot 353-353 above described and included between this latter lot and the Montreal River, being part of original lot Pt.353 of said plan and book of reference, bounded each side by the prolongation in straight line by the side lines of lot 353-353 and at each of its extremities by the Montreal River and said lot 353-353.With the buildings erected Ihereon, especially a house bearing civic No.1912 Des Tulipes Street, Town of Carignan and appurtenances.77.39 1.85 79.24 The lot No.353-P.385 of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly as described in the deed of sale by Notary Léo Lareau, registered under No.187035 excluding that part of the lot sold under No.330457.261.40 549.65 451.53 156.55 249.85 511.25 549.65 451.53 156.55 (a) A certain lot located on Demers Island in the Municipality of Chambly known and designated under No.357-185 of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly with all rights and appurtenances.This lot measures 50' in width by 100' in depth English measure, more or less.Deed of sale No.377980.March 19th/73.Notary Léo Lareau.(fc) The half northwest part of lot No.357-Pt.186 of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly, Deed of sale No.377980, March 19th/73.Notary Léo Lareau.The whole lot No.357-Pt.186) measuring 50' in width by 100' in depth before its subdivision.Soubiran.Maurice.P.320, P.320.Un emplacement situé en la ville de Carignan.comté de Ver-chères, composé savoir: a) d'une partie du lot originaire numéro trois cent vingt (P.320) au cadastre oïliciel de la paroisse de St-Joseph de Chambly.mesurant en largeur cent pieds et un dixième de pied (100.1) du côté est et cent pieds et quatre dixièmes de pied (100.4) du côté ouest; en longueur, cinq cent quatre-vingt-sept pieds (587') du côté nord et cinq cent soixante-seize pieds (576 ) du côté sud; bornée en front, à l'est, par le boulevard Ste-Thérèse (Route 47); en arrière, à l'ouest, par le terrain numéro 364 du canal Chambly, d'un côté, au nord, par partie du lot originaire numéro trois cent dix-neuf dudit cadastre et au sud par une autre partie dudit lot trois cent vingt appartenant à Harry Feinstein ou représentants; 971.02 158.16 1129.18 An emplacement situated in the Town of Carignan County of Verchères as follows: (a) A part of original lot 320 (Pt.320) of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly, measuring in width 100.1 feet on the east side and 100.4 feet on the west side; in length, 587 feet on the north side and 576 feet on the south side; bounded in front, to the east by Ste-Thérèse Boulevard (Route 47); at rear, to the west, by lot No.364 of the Chambly Canal; on one side, to the north by pan of original lot No.319 of said cadastre and to the south by another part of said lot No.320, property of Harry Feinstein or representatives; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 janvier 1975.107' année.n° 2 225 \t\tTaxes\tTaxes\t \t\tscol.\tscol.\tTaxes Propriétaires\t\tcath.\tprot.\tmunie.\tCadastre\t\t\t Owners\t\tCath.\tProt.\tMun.\t\tschool\tschool\ttaxes \t\ttaxes\ttaxes\t Total b) d'une partie du lot originaire numéro trois cent vingt (P.320) dudit cadastre, mesurant en largeur cent pieds et deux dixièmes de pied (100.2) par toute la profondeur comprise entre ledit boulevard Ste-Thérèse (Route 47) et la rivière Richelieu, dont les lignes nord et sud sont le prolongement imaginaire en droite ligne de l'ouest à l'est, des lignes nord et sud du terrain décrit au paragraphe a) de la présente description; bornée: à l'ouest, par ledit boulevard Ste-Thérèse (Route 47), à l'est par ladite rivière Richelieu, au nord par une lisière de terre (P.319) dudit cadastre et au sud par une autre lisière de terre (P.320 dudit cadastre) appartenant à Harry Feinstein ou représentants; c) d'une partie dudit lot originaire numéro trois cent vingt (P.320) dudit cadastre, mesurant en largeur cent pieds et quatorze centièmes de pied (100.14) du côté est et cent pieds (100\") du côté ouest, par une longueur de cinq cent vingt et un pieds (521') du côté nord et de cinq cent six pieds (506') du côté sud; bornée en front, à l'est, par ledit boulevard Ste-Thérèse (Route 47); en arrière, à l'ouest, par le terrain numéro 364 du canal Chambly; au nord par partie dudit lot originaire trois cent vingt appartenant à Harry Feinstein ou représentants et au sud, par une autre partie dudit lot trois cent vingt appartenant à Richard Choquette ou représentants; d) d'une partie du lot originaire numéro trois cent vingt (P.320) dudit cadastre, mesurant en largeur cent pieds et quatre dixièmes de pied (100.4) par toute la profondeur comprise entre ledit boulevard Ste-Thérèse (Route 47) et la rivière Richelieu, et dont les lignes nord et sud sont le prolongement imaginaire en ligne droite des lignes latérales nord et sud de la lisière décrite au paragraphe c de la présente description: bornée en front, a l'ouest, par ledit boulevard Ste-Thérèse (Route 47); à l'est, par la rivière Richelieu; au nord, par partie dudit lot trois cent vingt appartenant à Harry Feinstein ou représentants et au sud.par partie dudit lot trois cent vingt, appartenant â Richard Choquette ou représentants; e) d'une partie du lot originaire numéro trois cent vingt (P.320) dudit cadastre, mesurant en largeur deux cent cinquante-sept pieds et huit dixièmes de pied (257.8) du côté est et deux cent quarante-cinq pieds et trois dixièmes de pied (245.3) du côté ouest; par une longueur de cinq cent soixante-sept pieds (567') du côté nord et de cinq cent trente et un pieds et sept dixièmes de pied (531.7) du coté sud; bornée en front à l'est, par ledit boulevard Ste-Thérèse (Route 47); en arrière, à l'ouest, le terrain numéro 364 du canal Chambly; d'un côté, au nord par partie du lot 320 appartenant à Harry Feinstein ou représentants et du côté sud, par une autre partie dudit lot 320 appartenant audit Harry Feinstein ou représentants; f) d'une partie du lot originaire numéro trois cent vingt (P.320) dudit cadastre, mesurant en largeur deux cent cinquante-sept pieds et huit dixièmes de pied (257.8) par toute la profondeur comprise entre ledit boulevard Ste-Thérèse (Route 47) et ladite rivière Richelieu, dont les lignes nord et sud sont le prolongement imaginaire en ligne droite de l'ouest à l'est des lignes nord et sud du terrain décrit au paragraphe e de la présente description; bornée à l'ouest par ledit boulevard Ste-Thérèse (Route 47); à l'est, par ladite rivière Richelieu, au nord, par une partie dudit lot originaire 320 appartenant audit Harry Feinstein ou représentants; et au sud, par une autre partie dudit lot originaire 320 appartenant audit Harry Feinstein ou représentants.Avec toutes constructions y érigées et notamment une maison portant le numéro 3254 dudit boulevard Ste-Thérèse, en la ville de Carignan, comté de Verchères.grange, hangar, circonstances et dépendances.(b) A part of original lot 320 (Pt.320) of said cadastre measuring in width 100.2 feet by the whole depth included between said Ste-Thérèse Boulevard (Route 47) and the Richelieu River, of which the north and south lines are, in straight line from west to east, Ihe imaginary prolongation of the north and south lines of lot described in paragraph a of the present description; bounded to the west, by said Ste-Thérèse Boulevard (Roule 47), to the east by said Richelieu River, to Ihe north by a strip of land (Pt.319) of said cadastre and to the south by another strip of land (Pt.320) property of Harry Feinstein or representatives; (c) A part of original lot No.320 (Pt.320) of said cadastre, measuring in width 100.14 feet on the east side and 100 feel on the west side, by a length of 521 feet on Ihe north side and 506 feet on the south side; bounded in tront, lo the east, by said Ste-Thérèse Boulevard (Route 47); at rear, to the west, by lot No.364 of the Chambly Canal; to the north by part of said original lot 320 (Pi.320) property of Harry Feinstein or representatives and to the south, by another part of said loi 320 (Pl.320) property of Richard Choquette or representatives; (ft) A part of original lot No.320 (Pt.320) of said cadastre, measuring in width 100.4 feel by the whole depth included between said Ste-Thérèse Boulevard (Roule 47) and the Richelieu River and of which the north and south lines arc in straight line the imaginary prolongation of the north and south lateral lines of Ihe strip described in paragraph c of the present description; bounded in front, lo the west by said Ste-Thérèse Boulevard (Route 47); to the east, by the Richelieu River; to the north by pan of said lot 320 (Pt.320) property of Harry Feinstein or representatives and to the south, by the part of said lot 320 (Pt.320), property of Richard Choquette or representatives; (e) A pan of original lot No.320 (Pt.320) of said cadastre, measuring in width 257.8 feel on the east side and 245.3 feet on the west side; by a length of 567 feet to the north side and 531.7 feet to ihe south side; bounded in front to ihe east, by said Ste-Thérèse Boulevard (Route 47); at rear, to the wesl by the lot No.364 of the Chambly Canal; on one side, to the north, by part of lot 320 (Pt.320) property of Harry Feinstein or representatives and on the south side, by another part of said lot 320 (Pt.320) property of Harry t-einstein or representatives; (/) A pan of original lot No.320 (Pt.320) of said cadastre, measuring in width 257.8 feet by the whole depth included between said Ste-Thérèse Boulevard (Route 47) and said Richelieu River of which the north and south lines are in straight line, from wesl lo east, Ihe imaginary prolongation of lot described in paragraph e of Ihe present description; bounded lo the west by said Ste-Thérèse Boulevard (Route 47); to the east, by said Richelieu River, to Ihe north, by a part of the said original lot 320 (Pt.320) property of Harry Feinstein or representatives; and to the south, by another part of said original lot 320 (Pi.320) property of Harry Feinstein or representatives.With all buildings erected thereon and especially a house bearing civic No.3254 of said Ste-Thérèse Boulevard in the Town of Carignan, and appurtenances. 226 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11; 1975, Vol.107, No.Propriétaires Owners Cadastre Taxes\tTaxes\t scol.\tscol.\tTaxes cath.\tprot.\tmunie.Cath\tProt.\tMun.school\tschool\ttaxes taxes\ttaxes\t Total Laframboise, André .P.321 .Partie du lot P.321 mesurant cent (100) pieds dans sa ligne sud.quatre-vingts (80) pieds dans sa ligne nord, aussi quatre-vingts (80) pieds dans sa ligne ouest et soixante-quinze (75) pieds dans sa ligne est; le tout en mesure anglaise, et bornée, au nord, ainsi qu'à l'est, par une partie du lot 321 (P.321) transmise par décès de Alfred Laframboise sous le numéro 362030 devant Me Léo Lareau 19/5/72; au sud par partie du lot numéro trois cent vingt-deux (P.322); et du coté ouest, par le terrain du canal Chambly; â distraire également la partie vendue en venu de l'acte No 407658.Lapone L.O.(1969) Ltée .P.327 .Une tene située en la municipalité de Carignan faisant partie du loi numéro trois cent vingi-sept (P.327) du cadastre officiel de la paroisse de St-Joseph de Chambly.contenant en superficie environ cent douze arpents carrés (112 arp.car.); mesurant en front, au sud-est.mille trois cent quarante-cinq pieds (1,345') le long du tenain du canal Chambly; en amère, au nord-ouest, cent quatre-vingt-quatorze pieds (194'); d'un côté, soit d'abord vers le nord, trois mille quatre cent quatre-vingt-treize (3,493') puis, au nord-ouest, mille deux cent soixante-trois pieds et cinq dixièmes de pied (1.263.5'); puis, au nord, trois mille neuf cents pieds (3,900'): de l'autre côté, au sud.deux mille quatre cent quarante-quatre pieds (2,444-); puis, au sud-est mille cent trente-cinq pieds (1.135°) et; de nouveau au sud.trois mille neuf cent soixante (3,960') pieds, chacune des lignes latérales étant une ligne brisée et les mesures données sont à l'anglaise et plus ou moins.Ladite parue étant bornée, en front au sud-est par le tenain du cadastre de Chambly; en arrière au nord-ouest, par le lot 301-P.I dudit cadastre: d'un côté au nord, par partie du lot numéro trois cent vingt-cinq dudit cadastre et par partie du lot trois cent vingt-six pour une autre panic; au nord-ouest, par une autre partie dudit lot trois cent vingt-six; de l'autre côté, au sud-ouest, par partie dudit lot trois cent vingt-sept appartenant à Charles O'Reilly ou représentants; au sud-est, par une autre partie dudit lot trois cent vingt-sept appartenant encore à Charles O'Reilly ou représentants.Century Holdings Ltd.P.334 Un emplacement situé en la municipalité de Carignan.dans le comté de Chambly.étant une partie du lot numéro trois cent trente-quatre (P.334) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Joseph de Chambly, du côté ouest de la roule 47; mesurant cinquante (50') pieds de largeur sur cent pieds (100') de profondeur, mesures anglaises et plus ou moins; el borné comme suit: vers le sud par une vieille clôture parallèle à la ligne cadastrale des lots trois cent trente-quatre el trois cent trente et un (334 el 331) silué le long d'un fossé à une distance d'environ trois cents pieds de ladite ligne cadastrale et séparant cet emplacement de la partie résiduelle dudit lot trois cent trente-quatre, vers l'ouest cl le nord, par partie résiduelle dudit lot originaire numéro 334 et vers l'est par la route 47; Avec une bâtisse dessus érigée, portant le No 6562.chemin Ste-Thérèse.Carignan.Pro-Tint Ltée.346-P.|.Une partie du loi numéro un de la subdivision officielle du lot originaire numéro trois cent quarante-six (P.346-1) du cadastre de la paroisse St-Joseph de Chambly.connue et désignée dans l'acte de vente enregistré sous le No 405067; mesurant cent quatre- 298.81 41.28 340.09 Pan of lot Pt.321.measuring 100' on ils south line, 80' on ils north line, also 80' on ils west line, and 75' on its casl line; the whole in English measure and bounded, to the north and to the east by part of lot 321 (Pi.321) transmitted by death of Alfred Laframboise under No.362030 before Notary Léo Lareau May 19th/72; to the south by part of lot 322 (Pt.322); and to the west side, by pan of the land owned by the Chambly Canal; also excluding part of Ihe lot sold in virtue of the deed of sale No.407658.1376.68 938.45 286.62 2601.75 A land situated in the Municipality of Carignan, forming part of lot No.Pi.327 of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly.having a surface area of approximative^ 112 square acres; measuring in front to the south-east.1.345' along Ihe Chambly Canal lot; at rear, lo the north-west, 194'; on one side, namely to the north.3,493' and lo Ihe north-west 1,263.5' and to the north 3,900' on the other side lo Ihe south 2,444' and to the south-east 1.135' and again lo ihe south 3.960' each of the border lines, being a broken line and of English measure, more or less.The said pan being bounded in front to the south-east, by the lot owned by the Chambly Canal; at the rear lo the norlh-wesi, by lot 301-Pt.1 of said cadastre; on the north side by part of lot 325 and pan of loi 326 of said cadastre; to Ihe north-west, by another pan of said lot 326; on the other side to ihe south-west, by pan of lot 327 property of Charles O'Reilly or his representatives; to the south-east, by another part of lot 327 also the property of Charles O'Reilly or his representatives.367.84 42.17 39.52 449.53 An emplacement situated in the Municipality of Carignan in the County of Chambly, being part of lot 334 (Pt.334) of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly on the wesl side of Route 47, measuring 50' in width by 100' in depth, English measure, more or less; bounded as follows: lo the south, by an old fence paralled to the cadastre line of lots 334 et 331 situated along a dilch at a distance of approximately 300' of said cadastral line and dividing this emplacement from the remaining part of said lot 334, towards west and north, by remaining part of original lot No.334 and towards cast, by Route 47.With a building erected Ihereon bearing civic number 6562 St.Thérèse Road, Carignan.921.67 191.17 1112.84 A part of lot No.1 of Ihe official subdivision of original lot 346 (Pt.346-1) of the cadastre of the Parish of St.Joseph of Chambly.known and designated in the deed of sale registered under No.405067, measuring 180.5' along Ihe Grande Ligne Road on ihe GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il janvier 1975, 107' année, n° 2 227 Propriétaires Cadastre Owners Taxes\tTaxes\t scol.\tscol.\tTaxes cath.\tprot.\tmunie.Cath.\tProt.\tMun.school\tschool\ttaxes taxes\ttaxes\t Total vingts pieds et cinq dixièmes de pied (180.5') le long du chemin de la Grande ligne soit dans sa ligne sud-ouest, trois cent soixante-treize pieds et quatre dixièmes de pied (373.4') dans sa ligne ouest, cent vingt-sept pieds et un dixième de pied ( 127.1') en arrière dans sa ligne nord, quatre cent quatre-vingt-quinze pieds et cinq dixièmes de pied (495.5') dans sa ligne est.et bornée cetteditc partie dans sa ligne sud-ouest par le chemin de la Grande Ligne, à l'ouest par une partie du lot 340, dit cadastre, au nord par une partie du lot 345 dit cadastre et à l'est par le résidu dudit lot No 346-1.dit cadastre.Celte partie présentement décrite ayant une superficie totale de cinquante-cinq mille cent soixante-quinze pieds carrés et un dixième de pied carré (55,175.1 p.c.soit 1.499 arpent carré).Bessette.Jacques.358-1.P.31 Un certain emplacement silué sur la petite Ile Ste-Thérèse.dans le comté de Chambly et connu et désigné comme étant le lot numéro trente et un de la subdivision du lot numéro un de la subdivision officielle du lot originaire numéro trois cent cinquante-huit (358-1-31) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St Joseph de Chambly.mesurant en front, quarante-trois pieds et trois dixièmes de pied (43.3'); en arrière, soixante et onze pieds et trois dixième de pied (71.3') en profondeur, du côté nord, cent trente pieds et huit dixièmes de pied (130.8') et du côté sud.cent vingt-cinq pieds (125') le tout mesure anglaise et plus ou moins.Moins et à distraire la partie sud-est (de forme Uiangulaire) de la resubdivision numéro trente et un de la subdivision du lot numéro un de la subdivision officielle du lot originaire numéro trois cent cinquante-huit (358-1-P.S.E.31) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Joseph de Chambly.borné en front, à l'ouest par la rue (358-1-8); d'un côté, au sud-ouest par le lot numéro 358-1-30 et de l'autre côté, au nord par le résidu dudit lot numéro 358-1-31 tous dudit cadastre et au sud-est par la rivière Richelieu, mesurant cent vingt-cinq pieds (125') dans sa ligne sud-ouest, vingt-quaue pieds et un dixième de pied (24.1 ') dans sa ligne sud-est et environ cent vingt-six pieds (126') dans sa ligne nord, le tout mesure anglaise et plus ou moins.Avec bâtisse y dessus érigée et portant le numéro civique 8765.Ile Ste-Marie.Aubé.Jean-Guy .358-1, P 39 Un lot de terre situé sur l'île Sainte-Marie, autrefois petite Ile Ste-Thérèse.comté de Chambly.connu et désigné comme étant une partie du lot numéro trente neuf de la resubdivision officielle du lot numéro un de la subdivision officielle du lot originaire numéro trois cent cinquante-huit (P.358-1-39) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Joseph de Chambly.division d'enregistrement de Chambly.Ledit lot étant borné au nord par le lot numéro 358-1-40 des mêmes plan et livre de renvoi officiels, à l'est par le lot numéro 358-1-3 (rue).Au sud par une autre partie du lot numéro 358-1-39.et à l'ouest par la rivière Richelieu, et mesurant dans la ligne nord, cent vingt-huit pieds et neuf dixièmes de pieds (128.9').dans la ligne est.soixante-trois pieds et quatre-vingt-treize centièmes de pied (63.93'), dans les lignes sud dix-neuf pieds et douze centièmes de pied (19.12') suivant une courbe ayant un rayon de quinze pieds (15').trente-huit pieds et quinze centièmes de pied (38.15') et cent sept pieds et neuf centièmes de pied ( 107.09'), dans la ligne ouesl cent onze pieds et quatre-vingt-trois centièmes de pied (111.83') et contenant une superficie de douze mille huit cent trente-neuf pieds carrés el quatre dixièmes de pied carré (12.839.4').le tout mesure anglaise et plus ou moins.Avec loules les bâtisses y érigées.southwest line.373.4' on the wesl line.127.1' al ihe rear on the north line, 495.5' on the east line; and bounded this said pan on the southwest line by the Grande Ligne Road, to ihe wesl by a part of loi 340 of said cadasue.lo the north by a part of lot 345 of said cadastre and to the east, by the remainder of said loi No.346-1.This part presently described having a total area of 55175.1' sq.ft.(1.499 square acre).443.60 65.48 509.08 A certain emplacement situated on the small St.Thérèse Island, in the County of Chambly known and designated as being lot No.358-1-31 of the official cadastre of the Parish of St.Joseph of Chambly.measuring in front, 43.3'; al the rear, 71.3'; in depth, on the north side 130.8' and on the south side 125' Ihe whole English measure, more or less.Except and excluding from said lot.the southeast part (triangular) of the resubdivision No.31 of Ihe subdivision of lot No.1 of the official subdivision of original lot No 358 (358-1 -Pt.S.E.31) of the official cadastre of Ihe Parish St.Joseph of Chambly bounded in front to the west by ihe stfeet (358-1-8); on one side, to Ihe southwest by lot No.358-1-30 and on Ihe other side, to Ihe north, by the remainder of said loi 358-1-31 all of said ca-casire and to the southeast, by the Richelieu River, measuring 125' on its southwest line.24.1' on its southeast line and approximately 126' on its north line the whole in English measure, more or less.With the building thereon erected and bearing civic number 8765 St.Mary's Island.792.85 154.18 947.03 A certain lot.situated on Si-Mary's Island, formerly known as small Sl-Thérèse's Island.County of Chambly.known and designated as being part of loi 358-1-39 of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly of Ihe Registry Office for the Division of Chambly.The said loi being bounded lo ihe north by lot No.358-1 -40 of the same plan and book of reference, to Ihe east by lot No.358-1-3 (street), to the south, by another part of lot 358-1-39 and to Ihe wesl.by the Richelieu River and measuring on its north line 128.9'.on ils east line 63.93', on its south lines 19.12' following a curve having a radius of 15', 38.15' and 107.09'.on its wesl line 111.83' and having a surface area of 12.839.4' square feel, ihe whole English measure, more or less.With all buildings erected ihereon. 228 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 Ville de Carignan, cadastre officiel de la paroisse de St-Hubert Town of Carignan.official cadastre of the Parish of St.Hubert \t\tTaxes\tTaxes\t \t\tscol.\tscol.\tTaxes Propriétaires\t\tcath.\tprot.\tmunie.\tCadastre\t\t\tM un.Owners\t\tCath.\tProt.\t \t\tschool\tschool\ttaxes \t\ttaxes\ttaxes\t Total Nicolocakis, Andrew .82-41,42 .Nicolocakis, Andrew .82-43 a/to 45 incl Nicolocakis, Andrew .82-46, 47 .Mascoulis, Christos.82-63 .Chabala.Michael .82-65 .Plarinos, Denis & John .82-P.93.Un emplacement situé en la municipalité de Carignan dans le comté de Chambly, désigné et connu sous le numéro quatre-vingt-treize de la subdivision du lot originaire numéro quatre-vingt-deux (82 P.93) du cadastre officiel de la paroisse de St-Hubert; mesurant soixante-quinze pieds (75') de largeur (le long de la rue 82-12) par une profondeur de cent vingt pieds (120').le tout en mesure anglaise, plus ou moins; borné au nord-est par ladite rue (82-12); vers le sud-est.par la rue numéro 9 de ladite subdivision.Kros.Kurt.82-128.129 .¦ionta.Frank.82-P.135.136 Une partie de terrain située en la municipalité de Carignan dans le comté de Chambly, connue et désignée comme suit: a) de la partie du lot numéro cent trente-six de la subdivision du lot originaire numéro quatre-vingt-deux (82-136) du cadastre officiel de la paroisse de St-Hubert, division d'enregistrement de Chambly; mesurant 75 pieds de largeur par 121 pieds et 8/10 le long de la ligne nord-est et 121 pieds et 6/10 le long de la ligne sud-ouest; le tout en mesures anglaises, plus ou moins; b) de la partie du lot numéro cent trente-cinq de la subdivision du lot originaire numéro quatre-vingt-deux (82 P.135) du même cadastre de la paroisse de St-Hubert; mesurant 7 pieds et 16/100 de largeur par 121 pieds et 6/10 de profondeur; bornée vers le nord-ouest par la rue projetée No 18 de la subdivision 82 (82-18); vers le sud-est.par le lot originaire 83; vers le nord-est.par le lot 82-136 et vers le sud-ouest, par le résidu du lot 82 P.135 appartenant à Nokolaes Piriohos; mesure anglaise.Meir.Johannes .88-P.53 Un certain lot situé en la municipalité de Carignan, comté de Chambly, connu et désigné sous le numéro cinquante-trois de la subdivision du lot originaire quatre-vingt-huit (88 P.53) du cadastre officiel de la paroisse de St-Hubert, mesurant cinquante pieds en largeur par cent pieds de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise.À distraire la partie vendue dans l'acte No 332432.Schneller, Jacob .88-P.339 .Un emplacement situé en la municipalité de Carignan dans le comté de Chambly.connu el désigné sous le numéro trois cent trente-neuf de la subdivision du lot originaire numéro quatre-vingt-huit (88-339) du cadastre officiel de la paroisse de St-Hubert.$ 64.34 S 64.34 45.98 45.98 64.34 64.34 28.86 $ 47.04 75.90 .23.73 23.73 .116.98 23.52 140.50 That certain lot.situated in the Municipality of Carignan.County of Chambly; known under number as a part of the lot ninety-three of the official subdivision of the original lot eighty-two (82-Pt.93) of the Parish of St-Hubert, in the Registry Division of Chambly; measuring in width seventy-five feet (to wit along the street 82-12 and in rear), by a depth of one hundred and twenty feet, the whole in English measure more or less; bounded towards the northeast by the said street (82-12); towards the southeast, by the street number nine of the said subdivision.103.80 69.57 70.37 9.00 174.17 78.57 A piece of land, situated in Ihe Municipality of Carignan.County of Chambly.and composed: (a) of the lot number one hundred and thirty-six of the official subdivision of the original lot number eighty-two (82-136) of the official cadastre of the Parish of St-Hubert, in the Registration Division of Chambly; measuring in width seventy-five feet and in depth one hundred and twenty-one feet and eight tenths of one foot in its northeast line and one hundred and twenty-one feel and six tenths of one foot in its southwest line; the whole in English measure, more or less; (6 of thai part of the lot number one hundred and thirty-five of the official subdivision of the original loi number eighty-two (82-Pt.135) of the same cadastre of the Parish of St-Hubert; measuring in width seven feel and sixteen hundredths of one foot by a depth of one hundred and Iwenty-one feet and six tenths of one foot: bounded towards the north-west by the proposed street eighteen of said subdivision (82-18); towards the southeast, by tne original lot eighty-three (83); towards the northeast, by the said lot 82-136 and towards the southwest, by the remainder of said lot one hundred and thirthy-five of said subdivision (82-Pt.135) belonging to Nokoloas Piriohos; all measures are English measure.37.92 8.59 46.51 A certain lot located in the Municipality of Carignan, County of Chambly, known under number 88 Pt.53 of the official cadastre of the Parish of St-Hubert, measuring 50' in width and 100' in depth, English measure, more or less.Excluding part sold under the deed No.332432.62.31 62.31 An emplacement situated in Ihe Municipality of Carignan in Ihe County of Chambly, known and designated under No.88-339 of the official cadastre of the Parish of St-Hubert; measuring 50' in width by 138' in depth, more or less, and English measure. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° 2 229 Propriétaires Owners Cadastre Taxes\tTaxes\t scol.\tscol.\tTaxes calh.\tprot.\tmunie.Cath.\tProt.\tMun.school\tschool\ttaxes taxes\ttaxes\t Total mesurant cinquante pieds (50') de largeur par cent trente-huit pieds (138') de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise.Acte Me Paul Racz enregistre sous No 181158.7/1/59.Hadbawnik.Joseph.88-415.416 .Deed of Notary Paul Racz registered under No.181158.Jan.7th.1959.59.40 33.85 93.25 Cité de Chambly.cadastre officiel du village du Bassin de Chambly Town of Chambly.official cadastre of the Village of the Basin of Chambly Pearson.Rodolphe .P.16 .Un terrain vacant, situé en la cité de Chambly.dans le comté de Chambly.faisant partie du lot numéro seize (P.16) du cadastre officiel du village du Bassin de Chambly; ayant Iront sur la rue projetée ci-après décrite; mesurant en front, le long de ladite rue.ainsi qu'en arrière, soixante-quinze (75') pieds de largeur, par une profondeur de cent dix ( 110') pieds, mesure anglaise: borné comme suil: en front, vers le nord-ouest, par ladite rue projetée; vers le sud-est, par le lot vingt-six (26) dudit cadastre; au nord-est, par partie dudit lot seize (P.16) restant au vendeur et du côté sud-ouest, par partie dudit lot seize (P.16) restant au vendeur; dont la ligne sud-ouest se trouve à une distance de cent cinquante pieds (150) anglais de la ligne nord-est du terrain (P.16) vendu par le présent vendeur à Wilfrid Gauthier aux termes de l'acte enregistré sous le No 124607; les quatre angles dudit terrain étant droits.» Les placements Fortier Ltée.P.16 .Un certain immeuble composé de: a) Un terrain situé au village du Bassin de Chambly, dans le comté de Chambly.faisant partie du lot numéro seize (P.16) du cadastre officiel dudit village: sis du côté nord-est du chemin de Chambly (route Nationale 1 ); dont les lignes latérales nord-ouest et sud-est sont parallèles entre elles, et parallèles â la ligne de division des lots seize et vingt-six (16 et 26) du cadastre officiel dudit village: dont la ligne latérale sud-est se trouve à cent soixante-seize pieds de ladite ligne de division de ces lots; mesurant ce terrain cent dix pieds (110') de largeur, par cent vingt-deux pieds (122') du côté sud-est, et cent soixante-neuf pieds (169') du côté nord-ouest; et borné ce terrain, comme suit: au sud-ouest par ladite route provinciale, au nord-est et au nord-ouest par le résidu dudit lot seize et au sud-est par la rue Béique; b) Un autre terrain situé égalemenl en la ville de Chambly.mesurant sept pieds de largeur par une profondeur de cent soixante-sept pieds el un dixième dans sa ligne nord el cent soixante-quatre pieds et deux dixièmes dans sa ligne sud; el borné comme suit: à l'ouest, par le chemin Chambly (Route No 1).à l'est et au nord par une partie dudit loi originaire seize, el au sud par un autre partie du même lot et susdécrit.Ce terrain fait partie du lot originaire seize (16) du cadastre officiel du village du Bassin de Chambly: Toutes ces mesures sont anglaises el avec toutes les constructions y érigées et avec toutes les servitudes y attachées.Provencher.Mlle E.26-tl Provencher.Mlle E.26-42 Landry.Emile.27-61 Téueault.Yves .35-1 .Société de Gestion Senex.P-69 .$ 509.96 $ 322.18 S 832.14 A vacanl loi.situated in the City of Chambly, Counly of Chambly.being pan of lot No.16 (Pl.16) of the officiai cadastre of the Village of the Basin of Chambly: having its frontage, on the projected street hereafter described: measuring in from, along said sueet.also al ihe rear.75' in width by a depth of 110' English measure; bounded as follows: facing towards northwest, by the projected street; towards souihcast.by loi No.26 of said cadastre; to the northeast, by part of said lot No.16 (Pt.16) remaining to the vendor; and on the southwest side, by part of loi 16 (Pt.16) remaining lo the vendor: of which the southwest lines is at a distance of 150' English measure from ihe northeast line of lot 16 (Pi.16) sold by said vendor to Wilfrid Gauthier al ihe terms of the deed registered under No.124607; the four angles of the said loi being straight.29.96 1214.35 .1039.30 î H5.09 A certain unmovable made up of: (a) A lot situated in the Village of the Basin of Chambly.County of Chambly.being pan of lot No.16 (Pt.16) of the official cadastre of said Village located on the northeast side of the Chambly Road (National Roule 1); of which the northwest and southeast lateral lines are parallel and parallel al Ihe division line of lots 16 and 26 (16 and 26) of Ihe official cadastre of said Village; of which the southeast lateral line is at 176 feet, of said division line of these lois; this lot measuring 110 feet in width by 122 feet in depth on the southeast side, and 169 leet on Ihe northwest side; and this lot is bounded as follows: to ihe southwest by said Provincial Route, to the northeast and northwest by the remainder of said lot 16 and to Ihe southeast, by Béique Street: (b) Another lot also situated in the City of Chambly.measuring 7 feet in width by a depth of 167.1 feel on ils northerly line and 164.2 feet on its southerly line; bounded as follows: lo ine wesl.by the Chambly Road (Route No.1).to the east and north by part of said original lot 16, and lo the south by another part of the same above mentioned loi.This land is part of original lot 16 of Ihe official cadasue of the Basin of Chambly; All above measures are English and all building erected thereon are included.289.49 60.39 112.29 793.27 44.08 2.72 4.24 289.49 60.39 112.29 793.27 51.04 230 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.S \t\tTaxes\tTaxes\t \t\tscol.\tscol.\tTaxes Propriétaires\tCadastre\tcath.\tprot.\tmunie.Owners\t\tCath.\tProt.\tMun.\t\tschool\tschool\ttaxes \t\ttaxes\ttaxes\t Total L'extrémité sud-ouest du lot originaire numéro soixante-neuf (P.S.O.69) des plan et livre de renvoi officiels du village du Bassin de Chambly, bornée à un bout au sud-ouest par la rivière de Montréal, à l'autre bout au nord-est par le lot No 69-64.d'un côté au sud-est par une partie du lot originaire numéro soixante-quatorze (P.74) dudit plan, et de l'autre côté au nord-ouest par une partie du lot originaire numéro soixante-cinq (P.65) dudit plan.A distraire la partie vendue en vertu de l'acte No 355509.Sénécal, Louis-Paul Un emplacement situé en la cité de Chambly, comté de Chambly et ayant front sur le boulevard Sénécal; composé des lots Nos 69-57, 69-58 et 69 partie 56 du cadastre officiel du village du Bassin de Chambly et borné; vers le sud-ouest et à l'ouest, par la partie du lot 69-56 (nouvelle route No 1); et vers l'est, par le lot No 69 partie 56, la ligne sud-est étant située à 53 pieds au nord-est de la ligne centrale de la nouvelle route numéro 1, mais sauf et à distraire la partie du lot 69 partie 57 qui a fait l'objet d'un avis d'expropriation enregistré sous le numéro 250530.Avec la maison érigée portant le numéro 650, boulevard Sénécal de la cité de Chambly, comté Chambly.Société de Gestion Senex.69-P.76, 77 69-P.101 69-P.113 .1.Une partie du lot numéro soixante-seize de la subdivision du lot originaire numéro soixante-neuf (69-P.76) aux plan et livre de renvoi otliciels du village du Bassin de Chambly, de figure irrégu-lière et mesurant cinquante-six pieds et huit dixièmes de pied (56.8') au nord-ouest, cinquante-trois pieds et trois dixièmes de pied (53.3') à l'ouest, cinquante-deux pieds et neuf dixièmes de pied (52.9') au sud-ouest, soixante-quinze pieds au sud-ouest et cent trois pieds au nord-ouest (103') et bornée au nord-ouest par la rue 69-113, à l'ouest par le résidu dudit lot 69-76, au sud-ouest par le lot 69-77, au sud-est par une partie du lot 74 et au nord-est par le lot 69-75.2.Une partie du lot numéro soixante-dix-sept de la subdivision du lot originaire numéro soixante-neuf (69-P.77) dudit cadastre de figure rectangulaire et mesurant dix-huit pieds et deux dixièmes de pied (18.2') au sud-est.cinquante-deux pieds et neuf dixièmes de pied (52.9') au nord-est et cinquante-six pieds et trois dixièmes de pied (56.3') à l'ouest el bornée au sud-esl par une partie du lot 74, au nord-est par le lot 69-76 et à l'ouest par le résidu dudit loi 69-77.3.Une partie du loi numéro cent un de la subdivision du loi originaire numéro soixante-neuf (69-P.101) dudit cadastre de torme triangulaire et mesurant vingt-sept pieds el huit dixièmes de pied au sud-est.soixante-seize pieds et six dixièmes de pied au sud-esl.soixante-seize pieds et six dixièmes de pied au nord-esl et quatre-vingt-un pieds et cinq dixièmes de pied à l'ouest, et bornée; à l'ouest par le résidu dudil lot 69-101, au sud-est par la rue 69-113 el au nord-est par le loi 69-102.Toutes les dimensions ci-dessus sont des mesures anglaises et plus ou moins.4.Le loi numéro cent treize de la subdivision du loi originaire soixante-neuf (69-113) du cadastre officiel du village du Bassin de Chambly.A distraire la partie vendue en vertu de l'acte No 355507.The southwest extremity of original lot No.69 (P.S.W.69) of plan and book of reference of the Village of the Basin of Chambly, bounded at one end.lo Ihe southwest by the Montreal River, at the other end lo the northeast by lot No.69-64, to a southeast side by part of original lot No.74 (Pt.74) of the said plan and on the other side to the northwest, by part of original lot No.65 (Pt.65) of said plan.To exclude part sold in virtue ol the deed No.355509.814.62 2,113.43 An emplacement situated in the City of Chambly County of Chambly and having its frontage on Sénécal Boulevard: made up of lots No.69-57, 69-58 and 69 P.56 of the official cadastre of the Village of the Basin of Chambly and bounded: towards southwest and to the west, by part of lot 69-56 (New route 1); and towards east, by loi No.69 P.56, Ihe southeast line being located at 53 feet to the northeast from the central line of the new route No.1, except and to exclude part of lot 69 P.57 under the registered expropriation notice No.250530.With the house erected thereon bearing civic No.650 Sénécal Boulevard in the Cily of Chambly.County of Chambly.297.25 31.71 1,963.63 2.292.59 1.A part of lot No.76 of the subdivision of original lot No.69 (69-Pl.76) to the plan and book of reference of the Village of the Basin of Chambly, of irregular shape and measuring 56.8 feet to northwest.53.3 feel to the west.52.9 feet to the southwest, 75 feet to the southwest and 103 feet to the northwest and bounded: to Ihe northwest by the street No.69-113, to the wesl by the remainder of said lot 69-76, to the southwest by lot 69-77, lo Ihe southeast by part of lot 74 and to the northeast by lot 69-75.2.A part of lot No.77 of the subdivision of original loi No.69 (69-Pt.77) of said cadastre, of rectangular shape and measuring 18.2 feet lo the southeast.52.9 feet to the northeast and 56.3 feel to the wesl and bounded lo Ihe southeast by part of lot 74, to the northeast by lot 69-76 and to Ihe west by the remainder of said lot 69-77.3.A part of lot No.101 of the subdivision of original loi No.69 (69-Pl.101) of said cadastre, of triangular shape and measuring 21.8 teet to the southeast.76.6 feet to the northeast and 81.5 feet lo the west and bounded; to the west, by the remainder of said lot 69-101.to the southeast by the street No.69-113 and to the northeast by lot 69-102.All above dimensions are of English measures, more or less.4.Lot No.113 of Ihe subdivision of original lot No.69 (69-113) of the cadastre of the Village of Ihe Basin of Chambly.To exclude part sold under the deed of sale No.355507.69-P.56 a/to 58 incl____ 1.298.81 Les Habitations Chaume Les Habitations Chaume 69-146 69-147 84.34 94.69 526.58 610.92 501.87 596.56 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n\" S 231 Propriétaires Owners Cadastre Taxes\tTaxes\t scol.\tscol.\tTaxes cath.\tprot.\tmunie.Caih.\tProt.\tMun.school\tschool\ttaxes taxes\ttaxes\t Total Les Habitations Chaume.Les Habitations Chaume.Les Habitations Chaume.Les Habitations Chaume.Les Habitations Chaume.Les Habitations Chaume.Les Habitations Chaume.Les Habitations Chaume.Sénécal, Louis-Paul .Herrouin, Marc.Massicotte, Gilles et Clément .Massicotte, Gilles et Clément .Massicotte, Gilles et Clément .Un emplacement situé à l'est du chemin div cinquante-sept de la subdivision du lot originaire 157), connu et désigné comme lot (130-P.157-2) ciel du village du Bassin de Chambly, avec toutes y érigées, tel que décrit dans l'acte enregistré 363467.69-149 .118.23 532.39 650.62 69-152 .98.39 18.80 658.77 775.96 69-154 .56.08 11.86 42.10 110.04 69-155 .50.93 10.76 38.23 99.92 69-156 .38.38 8.07 24.28 70.73 69-207 .132.03 377.73 509.76 69-208 .113.54 312.31 425.85 69-209 .87.78 74.45 162.23 110-3 .152.02 263.92 415.94 111-7-2.7-3 .157.31 1.420.05 1.577.36 130-156 .136.25 136.25 130-156 .130.04 130.04 130-P.157-2 .403.80 403.80 isant le lot cent An emplacement, situated east of the road deviding lot 157 cent trente (130- of the subdivision of original lot No.130, known and designated du cadastre offi- as lot (357-Pt.157-2) of the official cadastre of the Village of les constructions the Basin of Chambly with all buildings erected thereon as de-sous le numéro scribed in deed registered under No.363467.Cité de Chambly, cadastre officiel de la paroisse St-Joseph de Chambly 7oH7i of Chambly, officiai cadastre of the parish of St.Joseph of Chambly Bicic.Mrs.Ivan.230-76 et/and 231-277 .Brisson, M.Laurent.231-28 .Bicic, Mrs.Ivan.231-192 .Bicic, Mrs.Ivan.231-276 .Terrasse Salaberry Inc.(a/s Simon Kirsch).267-148, 149.150 .Terrasse Salaberry Inc.(a/s Simon Kirsch).267-151 .Terrasse Salaberry Inc.(a/s Simon Kirsch).267-152 .Terrasse Salaberry Inc.(a/s Simon Kirsch).267-153 cl/and 267-154.Wlodarczyk.Mme V.G.268-147 .Ballester.Mr.John.268-156 .Beauchesne.M.Guy .268-267 .Beauchesne.M.Guy .268-268 .Beauchesne.M.Guy .268-279 .Mercuriades.M, Abraham.270-42 .Mercuriades.M.Abraham.270-43 .Montreal Chambly Development Corp.270-227 a/to 231 incl.Romanczuk, Mr.Franciszek .270-276 .Romanczuk, Mr.Franciszek .270-277 .Laplante, M.René.270-367 .Desgagné, M.André .270-395 .Soucy.M.Michel.270-445 .Gailer, Mme Maria P.270-P.589 .Un lot vacant situé dans la paroisse St-Joseph de Chambly.connu comme étant la subdivision cinq cent quatre-vingt-neuf du lot originaire deux cent soixante-dix (270-P.589) du cadastre officiel de la paroisse St-Joseph de Chambly.42.93\t\t$\t42.93 285.69\t\t\t285.69 29.61\t\t\t29.61 42.32\t\t\t42.32 161.00 $\t63.12 $\t122.49\t346.61 50.32\t19.50\t37.76\t107.58 41.35\t15.91\t30.82\t88.08 80.38\t31.34\t60.80\t172.52 49.69\t\t15.82\t65.51 49.69\t\t31.64\t81.33 49.69\t\t\t49.69 49.74\t\t\t49.74 49.74\t\t\t49.74 153.30\t\t\t153.30 153.30\t\t\t153.30 403.80\t75.40\t\t479.20 49.69\t\t\t49.69 49.69\t\t\t49.69 43.12\t\t\t43.12 42.57\t\t17.26\t59.83 61.59\t\t27.38\t88.97 86.75\t\t\t86.75 A vacant lot situated in known and designated as lot 270 (270-Pt.589) of St.Joseph of Chambly.the Parish of St.Joseph of Chambly, being the subdivision 589 of original Ihe official cadastre of the Parish of Gailer, Mme Maria P.270-P.590 .Un lot vacant situé dans la paroisse St-Joseph de Chambly, connu comme étant la subdivision cinq cent quatre-vingt-dix du loi originaire deux cent soixante-dix (270-P.590) du cadastre officiel de la paroisse St-Joseph de Chambly.$ 44.74 S 44.74 A vacant lot situated in the Parish of St-Joseph of Chambly, known and designated as being the subdivision 590 of original lot 270 (270-Pt.590) of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly. 232 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 Propriétaires Cadastre Total Owners Taxes\tTaxes\t scol.\tscol.\tTaxes cath.\tprot.\tmunie.Cath.\tProt.\tMun.school\tschool\ttaxes taxes\ttaxes\t 270-P.592 .-Joseph de Chambly.quatre-vingt-douze du 592) du cadastre offi- 270-P.593 .-Joseph de Chambly, quatre-vingt-treize du 593) du cadastre offi- Gailer, Mme Maria P.Un lot vacant situé dans la paroisse St connu comme étant la subdivision cinq cent lot originaire deux cent soixante-dix (270-P ciel de la paroisse St-Joseph de Chambly.Gailer, Mme Maria P.Un lot vacant situé dans la paroisse St connu comme étant la subdivision cinq cent lot originaire deux cent soixante-dix (270-P.ciel de la paroisse St-Joseph de Chambly.Marleau, M.Arthur .270-649 .Ducharme, M.Donat.272-113 .Ducharme, M.Donat.272-114 .Monlieu Investments (a/s H.Feinsteim).274-767-2 .Stoddart, Mrs.Anna.P.301.Un certain emplacement ayant front sur le Grand Boulevard, en la ville de Chambly, connu et désigné comme étant une partie du lot originaire trois cent un (P.301) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Joseph de Chambly, et étant de figure irrégulière et étant plus particulièrement décrit comme suit, savoir: Commençant à une borne de pierre sur la ligne separative des lots numéros trois cent soixante-quatre et trois cent un (364 et 301) (Canal Chambly), dudit point de départ ainsi déterminé, suivant la ligne separative des lots numéros trois cent un et trois cent soixante-quatre (301 et 364), dans une direction S.35°04' E., une distance de cent trente pieds et cinq dixièmes de pied (130.5') jusqu'à un point; de là; suivant une direction S.24°26' O., une distance de cent seize pieds el deux dixièmes de pied (116.2') jusqu'à son intersection avec la limite nord du chemin public: de la, suivant la dernière limite mentionnée dans une direction générale nord-ouest, une distance de cent douze pieds et neuf dixièmes de pied (112.9') jusqu'à un point; de là; suivant une direction N.24°26' E., une distance de cent soixante-douze pieds el cinq dixièmes de pied (172.5') jusqu'au point de départ.Formant une superficie de seize mille deux cent quarante-sept pieds carrés (16,247 pi, ca.), plus ou moins.Toutes les courses mentionnées sont astronomiques et les mesures ci-dessus mentionnées sonl en la mesure anglaise, en plus ou moins.À distraire la partie expropriée en vertu de l'acte 403884.Avec bâtisses dessus érigées portant le numéro 2344, du Grand Boulevard, en la ville de Chambly.McCutcheon, M.Yvon .Bâtisses sur / buildings on P.304 Bâtisses, propriétés de Yvon McCutcheon, érigées sur terrain de Mme Jeannette Vidal Harbec, connu sous le numéro de cadastre P.304 lequel est bomé comme suit: en front, à l'est, par le lot 305, par le terrain du Canal Chambly et des lots 309 el 311; en arrière, à l'ouesl par le lot 301; du côté nord, partie par le loi 305 el partie par le lot 303 et du côté sud, partie par le loi 313 el partie par le lot 309 sauf et à distraire la partie du lot 304 sise au sud-ouest du Canal Chambly, et léguée à Raymond Harbec.78.16 78.16 A vacant loi situated in the Parish of St-Joseph of Chambly, known and designated as being Ihe subdivision 592 of original loi 270 (270-Pt.592) of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly.109.50 109.50 A vacant lot situated in the Parish of St-Joseph of Chambly, known and designated as being the subdivision 593 of original loi 270 (270-Pt.593) of the official cadastre of the Parish of St-Joseph of Chambly.36.04 32.59 32.49 11.21 408.08 3.03 36.04 32.59 32.49 14.24 408.08 A certain emplacemenl with the frontage on Grand Boulevard in the City of Chambly, known and designated as being part of original lot 301 (Pt.301) lo the plan and book of reference, of the Parish St-Joseph of Chambly of irregular shape and being more particularly described as follows: Starting at a stone landmark on the dividing line of lots 364 and 301 (Chambly Canal), from said starting landmark so determined, following the dividing line of lots 301 and 364.in a S.35°04' E direction, a distance of 130.5 feel lo a landmark; from there, following a S.24°26' W.a distance of 116.2 feet up to the intersection of the north limit of the public road; from thereon, following [he last mentioned limit, in a northwest general direction, a distance of 112.9 feet lo a landmark; from thereon, following a N.24°26' E.a distance of 172.5 feet to the starting point.For a tola! surface area of 16,247 square feel, more or less, English measure, to exclude part expropriated under No.403884.Wiih buildings erected thereon and bearing civic No.2344 Grand Boulevard in the Cily of Chambly.884.07 747.47 1.631.54 Buildings properly of Yvon McCutcheon erected on Mrs.Jeannette Vidal Harbec's lot known under cadastral No.Pt.304 which is bounded as follows; in front lo the east, by lot 305, by the Chambly Canal piece of land and lots 309 and 311; at the rear, lo ihe west, by lot 301; on Ihe north side, part of loi 305 and part of lot 303 and on the south side, part of lot 313 and part of lot 309, except and to exclude part of lot 304, to Ihe southwest of the Chambly Canal legated lo Raymond Harbec.Archambault, M.Antonin .313-P.4, 313-P 313-P.4 .1.Un emplacement situé en la ville de Carignan, au lieu appelé 270.29 52.47 75.42 7.03 345.71 59.50 1.An emplacement situated in the Town of Carignan called «Pine Heights», ayant front sur le chemin public qui suit le côté .\"Pine Heights\" with the frontage on Ihe public road along the west ouest du Canal Chambly, étant une partie du loi numéro sept de la side of the Chambly Canal, being part of lot 7 of Ihe official subdi- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n\" g 233 Propriétaires Owners Cadastre Taxes\tTaxes\t scol.\tscol.\tTaxes cath.\tprot.\tmunie.Cath.\tProt.\tM un.school\tschool\ttaxes laces\ttaxes\t Total subdivision officielle du lot originaire numéro trois cent treize (313-P.7) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Joseph de Chambly, comlé de Chambly, mesurant cinquante pieds de largeur au chemin public et à la profondeur, sur une profondeur d'environ cent dix-sept pieds, plus ou moins, mesure anglaise, et borné: vers l'est, par ledit chemin public; vers le sud, par la ligne de division sud dudit lot No 313-7; à l'ouest, par une partie du même lot appartenant à M.Miriam Thompson ou représentants; et au nord, par une autre partie dudit loi No 313-7 appartenant à Mlle Ann M.Foster el al ou représentants.2.Un morceau de terrain situé au même lieu et adjacent à celui sus-décrit, ayant front sur le chemin public qui longe le côté ouest du Canal Chambly, formant partie du loi numéro quatre de la subdivision officielle du loi originaire numéro trois cent treize (313-P.4) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Si-Joseph de Chambly, comté de Chambly, mesurant cinquante pieds de largeur sur ledit chemin public et en arrière, par une profondeur d'environ cent dix-huit pieds dans sa ligne nord et d'environ cent vingt pieds dans sa ligne sud, le tout plus ou moins et à la mesure anglaise, borné: à l'est, par ledit chemin public; au nord, par la ligne de division entre ledit loi No 313-4 et le susdit lot No 313-7; en arrière, à l'ouest, el du côté sud, par le résidu dudit lot No 313-4.3.Un morceau de terrain situé au même endroit, adjacent à celui en second lieu sus-décrit, ayant front sur le chemin public qui longe le côté ouest du Canal Chambly, faisant partie du lot numéro quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro trois cent treize (313-P.4) desdits plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Joseph de Chambly.mesurant soixante-quinze pieds en largeur sur le chemin public susdit et en arrière, sur une profondeur d'environ cent vingt pieds dans sa ligne nord et d'environ cent vingt-deux pieds dans sa ligne sud, mesure anglaise et plus ou moins, et borné: à l'est, par ledit chemin public; au sud, par la rue Richelieu (lot No 313-3); au nord, par la ligne de division entre le lot présentement décrit el le loi formant partie dudit loi No 313-4 ci-dessus décrit en second lieu; et à l'ouest, par le résidu dudit lot No 313-4 appartenant à Dame Miriam Thompson-Kingsley ou représentants.Avec la maison et toutes les constructions y érigées.Choquette.M.Richard.P.320 .Une terre située en la paroisse de St-Joseph de Chambly, comté de Chambly, mesurant trois arpents de largeur sur quarante arpents de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, le plus ou moins devant tourner au profit ou à la perte du débiteur, quelque grande que soit la différence, formant partie du lot numéro trois cent vingt (P.320) aux plan et livre de renvoi de ladite paroisse, et bornée: en front par la rivière Richelieu, en profondeur par le lot numéro trois cent un desdits plan et livre de renvoi officiels, d'un côté au nord par une autre partie dudit lot numéro trois cent vingt, appartenant à Joseph Choquette représentant Wilfrid Harbec, et de l'autre côté au sud, pour la plus grande partie, par une autre partie du même lot No 320, appartenant à Victor Riberby el pour le reste par le lot 321 desdits plan et livre de renvoi, appartenant à Alfred et Onésime Laframboise.avec bâtisse sus-érigée portant le numéro civique 4068, Rang Ste-Thérèse, et six chalets sus-érigés.vision of original lot No.313 (313 Pt.7) of the plan and book of reference of the Parish of St-Joseph of Chambly, County of Chambly, measuring 50 feet in width lo the public road and to the depth, by a depth of approximately 117 feet, more or less, English measure and bounded: towards east, by said public road; towards south, by the south division line of said lot No.313-7; lo the wesl by pan of Ihe same lot, property of Mrs.Miriam Thompson or representatives; and to the north, by another part of said lot 313-7, properly of Miss Ann M.Foster and al or representatives.2.A piece of land situated in the same locality and contiguous to the above described lot, with the frontage on the public road along the west side of Ihe Chambly Canal, being pan of lot No.4 of the official subdivision of original loi 313 (313-Pt.4) of the plan and book of reference of the Parish of Si-Joseph of Chambly, County of Chambly, measuring 50 feel in width on said public road and at the rear by a depth of approximately 118 feet in its north line and 120 feet in its south lime, the whole, more or less, English measure, bounded; to the east by said public road; to the north by the division line betwen said lot 313-4 and the above mentioned lot 313-7; at the rear, to the west and south sides, by the remainder of said lot 313-4.3.A piece of land situated in the same locality an contiguous to above mentioned lot 313-Pt.4 with the frontage on the public road along the west side of Ihe Chambly Canal, being part of lot No.4 of the official subdivision of the original lot 313 (313-Pt.4) of said plan and book of reference of the Parish of St-Joseph of Chambly, measuring 75 feet in width on the said public road and at rear by a depth of approximately 120 feet on ils north line and approximately 122 feet on its south line, English measure, more or less, and bounded: to the east, by said public road; to the south, by Richelieu Street (lot 313-3); to the north, by the division line betwen Ihe presently described loi and lot forming part of said lot 313-4 here-above described; and to Ihe west, by the remainder of said lot 313-4 property of Mrs.Miriam Thompson Kingsley or representatives.With the house and all buildings erected thereon and appurtenances.$ 809.11 $ 241.72 $ 1,050.83 A land situated in the Parish of St-Joseph of Chambly, County of Chambly.measuring 3 acres in width by 40 acres in depth.English measure, more or less, the more or less reverting to the profil of loss of the debtor how great should the difference be, being part of lot No.320 (Pt.320) of the plan and book of reference of said Parish and bounded: in front by the Richelieu River, in depth by lot No.301 of said plan an book of reference, on one side to the north by another part of said loi No.320, property of Joseph Choquette, representing Wilfrid Harbec, and on Ihe other side to the south, for the greater part, by another pari of Ihe same lot No.320.property of Victor Riberby and for the difference by lot No.321 of said plan and book of reference, property of Alfred and Onésime Laframboise.with the building erected thereon, bearing civic number 4068 Rang St.Thérèse and six (6) bungalows erected thereon. 234 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 Cité de Chambly, cadastre officiel du village du Canton de Chambly Town of Chambly.official cadastre of the village of the Canton of Chambly Propriétaires Owners Cadastre Taxes\tTaxes\t scol.\tscol.\tTaxes cath.\tprot.\tmunie.Cath.\tProt.\tMun.school\tschool\ttaxes taxes\ttaxes\t Total Burelle.Jacques .P.50 .Un terrain vacant, situé en la cité de Chambly, comté de Chambly et ayant fronl sur la rue Centre; faisant partie du lot de terre numéro cinquante (P.de 50) du cadastre officiel du village du canton de Chambly; mesurant toute la largeur dudit lot par une profondeur de deux cents pieds, m.a.et borné; en front, par la rue Centre; en arrière, par l'emplacement (P.50) de H.P.Beauvais ou représentant; d'un côté, par partie du loi numéro cinquante et un (P.de 51) de Dame Cora Denault-Besselte ou représentants; et de l'autre côté, par l'emplacement (P.49) de Dame René Côté; avec la maison y érigée, portant le No civique II.de la rue Centre, circonstances et dépendances.D'Ulivo.Jean .P.90 .Un emplacement situé en la cité de Chambly el faisant partie du lot numéro quatre-vingt-dix (90) aux plan et livre de renvoi officiels du village de Chambly canton el borné comme suit: 1.En fronl par la rue Bourgogne el mesurant trenle-sept pieds (37') de largeur dans cette ligne, mesure anglaise.2.En arrière par la rue Galipeault el mesurant quinze pieds (15') dans cette ligne.3.Du côlé sud-ouesl par le résidu dudit lot numéro quatre-vingt-dix (90) appartenant au Théâtre Chambly Limitée et mesurant deux cent soixante-dix pieds (270') de longueur.4.Du côté nord-est par le résidu dudit loi numéro quatre-vingt-dix (90) appartenant à M.Rolland Daousl cl Lina Dubuc, son épouse, el mesurant deux cent qualre-vingl-dix pieds (290') dans celle ligne.Le tout, plus ou moins mesure anglaise et avec toutes les bâtisses dessus construites et portant le numéro civique 2304-08, rue Bourgogne, cité de Chambly.Longwood Development Corp.96-2 .Longpré, Leopold.98-6 .Dubuc.Mme Monique.113-P.1.113-P.6.P.114.115-19 Un certain emplacement ayant front sur la rue Bourgogne en la ville de Chambly.connu et désigné au cadastre officiel du village du canton de Chambly, comme étant composé: 1.du lot numéro six de la subdivision officielle du loi originaire numéro cent treize (113-6), moins cependant celle partie dudit numéro qui a été resubdivisée et qui est présentement connue sous le numéro 113-6-1; 2.du lot numéro dix-neuf de la subdivision officielle du loi originaire numéro cent quinze (115-19); 3.du lot numéro un de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent treize (113-1), moins cependant celle partie dudit numéro, de forme irrégulière, mesurant en front sur la rue Bourgogne cinquante-deux pieds et quaue dixièmes de pied, d'un côté vers le nord quaue-vingt-dix-neuf pieds, à l'arrière vers l'ouest el le sud-ouesl quarante-neuf pieds el cinq dixièmes de pied el quarante et un pieds el (rois dixièmes de pied, de l'autre côté vers le sud el le sud-esl quarante-deux pieds et sept dixièmes de pied et quarante et .$ 814.22 $ 367.78 $ 1,182.00 A vacanl lot, situated in the City of Chambly, County of Chambly with the frontage on Center Sueet; being part of lot No; 50 (Pt.50) of the official cadastre of the Village of Ihe Township of Chambly; measuring Ihe total width of said loi by 200 feel in depth EM.and bounded: in fronl by Center Street; at Ihe rear by Ihe emplacement (Pi.50) of H.P.Beauvais of his representative; on one side by part of lot 51 (Pt.of 51) of Mrs.Cora Denaull-Bessette ot her representatives; and on the other side by the emplacement (Pt.49) of Mrs.René Côté; with Ihe house erected thereon, bearing civic No.27 Center Streel and appurtenances.649.58 649.58 An emplacement situated in the Cily of Chambly, being part of loi No.90 to ihe plan and book of reference of Ihe Village of the Township of Chambly and bounded as follows: 1.In front, by Bourgogne Street and measuring 37 feet in width in this line, English measure.2.At Ihe rear, by Ualipeault Stteet and measuring 15 feet in this line.3.To the southwest side, by the remainder of said lot 90.property of Chambly Theater Ltd., and measuring 270 feet in length.4.To the northeast side, by the remainder of said lot 90 property of Mr.Rolland Daoust and Lina Dubuc.his spouse, and measuring 290 feet in this line.The whole, more or less.English measure and with all buildings thereon erected and bearing civic No.2304-08 Bourgogne St.City of Chambly.59.08 59.08 .1.161.62 956.06 2,117.68 .4.782.18 3.542.07 8,324.25 A certain emplacement with the frontage on Bourgogne Street in ihe City of Chambly, known and designated to the official cadasue of the Village of Ihe Township of Chambly as being as follows: 1.Loi No.6 of Ihe official subdivision of original lot No.113 (113-6) less however this part of said number which has been re-subdivised and is presently known under No.113-6-1; 2.Lot No.19 of the official subdivision of original lot No.115 (115-19); 3.Lot No.I of the official subdivision of original lot No.113 (113-1), less however this part of said number, of irregular shape, measuring in front on Bourgogne Street 52.4 feet, on one side towards north 99 feel, at the rear towards wesl and to the southwest 49.5 feet and 41.3 feet, on the other side towards south and southeast 42.7 feet and 41.2 feet, English measure, more or less and bounded as follows: in front by Bourgogne Street, to the north by part of number 112, at the rear towards west and south- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, i»° 2 235 Propriétaires Cadastre Owners un pieds el deux dixièmes de pied, mesure anglaise el plus ou moins el bornée comme suil: en front par la rue Bourgogne, au nord par une partie du numéro 112, à l'arrière vers l'ouest et le sud-ouest par d'autres parties dudit numéro 113-1 et de l'autre côté vers le sud par la partie du numéro 114 ci-après décrite et vers le sud-est par une autre partie dudit numéro 113-1; 4.du lot numéro cent quatorze (114,), moins cependant celte partie dudit numéro mesurant quarante-deux pieds et sept dixièmes de pied dans sa ligne nord, quatorze pieds et un dixième de pied dans sa ligne sud-ouest, vingt-cinq pieds dans sa ligne sud el six pieds et sept dixièmes de pied dans sa ligne sud-est et bornée comme suit: au nord par partie dudil numéro 113-1 ci-dessus distraite el des autres côtés au sud-ouesl.sud el sud-est par le résidu dudit numéro 114.Taxes\tTaxes\t scol.\tscol.\tTaxes cath.\tprot.\tmunie.Cath.\tProt.\tMun.school\tschool\ttaxes taxes\ttaxes\t Total west by other parts of said lot No.113-1 and on the side towards south by part of No.114 hereafter described and towards southeast by another part of said lot 113-1; 4.Lot No.114, less however Ihis part of said number measuring 42.7 feel on its north line, 14.1 feet on its southwest line, 25 feet on ils south line and 6.7 feet on its southeast line and bounded as follows; to the north by part of said No.113-1 hereabove excluded and of the other sides to Ihe southwest, south and southeast by the remainder of said lot No.114.La Commission municipale de Québec, par résolution en date du 4 décembre 1974, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux consécutifs, appartenant au même propriétaire, conformément aux articles 416 et suivants de la Loi de l'instruction publique.Donné à St-Bruno de Montarville, ce 26e jour du mois de décembre 1974.Le directeur général, Pierre Lépine, ca.59540-2-2-0 The Québec Municipal Commission, upon a resolution passed on the 4th day of December 1974, has authorized an abridged enumeration of consecutive cadastral numbers of immovables belonging to the same owner, according to the articles 416 and following of the Québec Education Act.Given at St.Bruno de Montarville.this 26th day of December 1974.Pierre Lépine, c.a., Director-General.59540-2-2-o Municipalité du comté de Stanstead Avis est par la présente donné par Jean-Paul Asselin, secrétaire-trésorier de la municipalité du comté de Stanstead, que les immeubles ci-après mentionnés seront vendus à l'enchère publique, au bureau d'enregistrement à Stanstead, P.Que., où le Conseil de Comté tient ses sessions, JEUDI, le TREIZIEME jour de MARS 1975, à DIX heures de l'avant-midi, pour non-paiement des taxes dues et les frais encourus, à moins que le tout ne soit payé avant la vente.Permission a été accordée à la municipalité du comté de Stanstead, par la Commission municipale du Québec, d'énumérer en abrégé les numéros cadastraux des immeubles ci-dessous mentionnés, et cela en date du 18 décembre 1974.Municipality of the County of Stanstead Notice is hereby given by Jean-Paul Asselin.Secretary-Treasurer of the Municipality of Stanstead County, that the immovables hereinafter mentioned will be sold by public auction, in the Registred Office.Stanstead.P.Que., where the County Council holds its meetings, on THURSDAY, the THIRTEENTH day of MARCH.1975, at TEN o'clock in the forenoon, for non-payment to the taxes due and of the costs incurred, unless the whole by paid before the sale.Permission has been granted to the Municipality of Stanstead Counly.by the Québec Municipal Commission, to list in an abbreviated form the cadastral numbers of the immovables hereinafter mentioned, the foregoing on December 18.1974. 236 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 Commission scolaire de Magog el Lennoxville Magog School Commission and Lennoxville \t\t\t\tTaxes\tTaxes\tIntérêts\t Nom des propriétaires\tSuperficie\t\tRang\tmun.\tscolaires\tet frais\tTotal \t\tLots Nos\t\t\t\t\t Names of proprietors\tArea\t\tRange\tM un.\tSchool\tInterest\t \t\t\t\ttaxes\ttaxes\tand costs\t \t\t1588-93 .\t\t$8.50\t$13.22\t$3.24\t$ 24.96 Forand, Denis.\t\tP.1350, 1351 .\t\t\t215.23\t23.64\t238.87 Tourigny, Olivier.\t\t212-213.\t\t\t668.13\t49.13\t717.26 \t\tP.254.255-4 .\t\t\t784.31\t82.95\t867.26 Labrador Acceptance Corp.\t\tP 6-235 .\t19\t16.16\t25.45\t6.21\t47.82 \t\tP.6-236 .\t19\t\t\t\t \t\t175 P.176\t\t159.38\t408.36\t40.16\t607.90 \t\t169 P 168\t\t382.08\t889.87\t78.57\t1.350.52 \t\tP.72.P.73 .\t\t204.00\t224.58\t34.35\t462.93 Martin.Kenneth .\t\tP.447 .\t\t486.20\t980.21\t80.51\t1.546.92 Concep Opec Inc.\t\t\t\t\t\t\t381.84 \t\t76.\t\t\t367.64\t14.20\t \t\t\t\t\t\t\t Corporation municipale du canton de Barnston Municipal Corporation of the Barnston Township \t84.63 acres .11.87 acres\tP.24, P.25C .P.16-9 .\t11\t$21.56\t\t$2.98\t$24.54 \t\t\t\t9.60\t\t3.12\t12.72 \t\tP.17-5 .\t4\t\t\t\t \t\tP.17-9 .\t4\t\t\t\t \t\tP.17-8 .\t4\t\t\t\t Ferland, Alphonse.\t4.074 p.c/sq.ft.14.810 p.c/sq.ft.10,000 p.c/sq.ft.12,762 p.c/sq.ft.145.87 acres.\tP.16-8 .16-19-2 .\t4 4\t0.28\t\t1.02\t1.30 Tremblay, Roméo.\t\t16-D .\t2\t2.32\t\t2.00\t4.32 Gagné.Lise (Dufresne).\t\tP.21-A.\t3\t2.10\t\t2.00\t4.10 \t\tP.24B, 24C .28-A .\t1\t21.68\t$72.32\t15.04\t109.04 Tremblay, Roméo & Georges .\t\t\t10\t40.26\t\t4.85\t45.11 \t\t28-B.\t9\t\t\t\t Gendrcau J.B Succ.\t33,541.2 p.c/sq.ft.\t20G .\t3\t4.76\t\t2.00\t6.76 \t\t\t\t\t\t\t Municipalité de Beebe Plain \u2014Municipality of Beebe Plain Wayne Lavers .,\t\t33.\t\t\t$146.17\t$1.00\t$147.17 Savage, Frank or David Audet.\t\t130.\t\t\t251.72\t17.41\t269.13 Gordon.Archer & Wm.Archer.\t\t135.\t\t\t20.56\t1.29\t21.85 Elliott Garage Rcg'd\t\t90.\t\t\t402.92\t16.31\t419.23 \t\t44.\t\t$ 170.00\t\t0.50\t170.50 \t\t\t\t\t\t\t Commission scolaire de Coaticook et Lennoxville Coaticook School Commission and Lennoxville Auberge de la Tourelle Lanciaux.Jules Succ.Trudeau.J.B.Gervais.Jean-Marie .Gervais.Jean-Marie .Herménégilde Dubois .17-5-1 .(733-5-1 .2060.2061 .437-2.445 (rue Forest) |437-2 (rue Yves) 17-11-23 .$190.05\t$7.93\t$197.98 14.74\t3.78\t18.52 6.31\t5.15\t11.46 344.98\t26.35\t371.33 31.53\t1.12\t32.65 123.09\t9.84\t132.93 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° S 237 Nom des propriétaires Names of proprietors\tSuperficie Area\tLots Nos\tRang Range\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes scolaires School taxes\tIntérêts et frais Interest and costs\tTotal Benoit, Gilles.\t\t840-1, 841-1 .685-1.685-2 685-3, 684-2 686-1 17B-46.\t\t\t330.00 993.78 1,850.96\t43.87 136.92\t330.00 1,037.65 1.987.88 Corporation municipale du canton de Magog (Bolton) Municipal Corporation of the Township of Magog (Bolton) Benoit, Francis et (Directeur des Vétérans) Mitson, Alton.Brousseau, Gérard et (Directeur des Vétérans) West.William E.Delorme, Roger Mme .Charbonneau.Emest.Lamarre, François.Corriveau, Noël .100 acres io,: \t\tP.IB \t\tP.1C /sq.\tft.\t4B-18 Itq\tft.\t5B-26 \tft.\t5B-27 \t\tP.IF \t\t1-4 ./sq.\tft.\t2A-7 \t\tP.2A /sq.\tft.\t2B-8 \tft.\t4-136 14\t$47.60\t$155.48\t$26.59\t$229.67 16\t131.40\t583.55\t18.21\t733.16 16\t153.20\t448.14\t70.42\t671.76 16\t\t\t\t 16\t\t\t\t 17\t62.20\t338.76\t15.62\t416.58 22\t118.40\t301.81\t49.56\t469.77 22\t\t821.39\t52.48\t873.87 22\t\t\t\t 22\t\t18.74\t2.31\t21.05 22\t49.60\t138.40\t15.56\t203.56 Corporation municipale du canton de Magog (Hatley) Municipal Corporation of the Township of Magog (Hatley) Bédard.Léo .Bédard, Léo .Bélanger, Jean-Guy .Bousquet.Marcel.Couturier, Léonard.Chrétien, P.-E.Drouin, Gérard Mme.Godue, Laurette Mme .Hamel.Jean-Guy .Lambert.Rodolphe.Langlois, Gilles.Lanoville, Lucien.Burkewitz Oil Corp.Dév.Lac Crystal (Magog) Inc Meldrum, Douglas .Mitchell, James.Strange, Dorothy Mrs.Byers, Daniel .Dév.Lac Crystal (Magog) Inc.Macey.Ethan .Bouffard, Donat .Dév.Lac Crystal (Magog) Inc.Hiebert, J.Nome.Cecil & Standish.H- Plowright.Arnold Mrs.5.025 p.c./sq.\tft.\t3C-'/2 191 .10,000 p.c./sq.\tli.\t3C-115.15.000 p.c./sq.\tft.\t17A-26 .12,948 p.c./sq.\tli.\t17A-30 .2,100 p.c./sq.\tft.\t17C-42.9,485 p.c./sq.\tft.\t1D-9 .2,500 p.c./sq.\tft.\t2À-'/« 57.5.000 p.c./sq.\tft.\t3C-'/2 90 .12.000 p.c./sq.\tft.\t17A-14 .\t\t17C-14.4,450 p.c./sq.\tft.\t2A-'/2 66 .5,000 p.c./sq.\tft.\t2A-'/2 37n.3.770 p.c./sq.\tft.\t2A-'/2 145.4,067 p.c./sq.\tft.\t3C-P.108 .2,140 p.c./sq.\tft.\t3C-'/23n.,2,560 p.c./sq\tft.\t3C-'/i 188 .5,100 p.c./sq.\tft.\t3C-'/2 192 .5,150 p.c./sq.\tft.\t2A-'/2 255 .6,660 p.c./sq.\tft.\t3C-122.4.350 p.c./sq.\tft.\t3C-'/2 123 .6,630 p.c./sq.\tft.\t3C-127.5,300 p.c./sq.\tft.\t2A-'/i74.5.007.5\t\t2A-'/2 118 .p.c./sq.ft.\t\t 7,450 p.c./sq.\tft.\t2A-'/2 151 .5,000 p.c./sq.\tft.\t2A-7i 190 .5.000 p.c./sq.\tft.\t3C-'/2 153n.5.000 p.c./sq.\tft.\t3C-V> I46n 13\tS 8.40\t$ 27.45\t$8.01\t$43.86 13\t14.00\t45.73\t9.89\t55.75 13\t\t196.35\t12.49\t208.84 13\t\t\t\t 12\t\t\t\t 13\t110.00\t273.36\t43.92\t427.28 13\t5.60\t18.29\t6.49\t30.38 13\t8.40\t\t4.26\t12.66 13\t70.60\t346.40\t44.63\t461.63 12\t\t\t\t 13\t31.00\t90.72\t9.53\t131.25 13\t\t27.45\t4.16\t31.61 13\t12.60\t36.45\t12.25\t61.30 13\t8.40\t27.45\t9.01\t44.86 13\t8.40\t27.45\t8.51\t44.36 13\t\t\t\t 13\t59.20\t128.03\t22.63\t209.86 13\t\t44.19\t2.96\t47.15 13\t16.80\t44.19\t8.48\t69.47 13\t\t\t\t 13\t26.80\t88.36\t7.47\t122.63 13\t16.20\t47.00\t13.28\t76.48 13\t12.60\t35.64\t10.21\t58.45 13\t12.60\t35.64\t10.21\t58.45 13\t12.60\t35.64\t10.21\t58.45 13\t12.60\t35.64\t10.21\t58.45 13\t12.60\t35.64\t10.21\t58.45 23S QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 Nom des propriétaires Names of proprietors Superficie Area Lots Nos Rang Range Taxes mun.Mun.taxes Taxes scolaires School taxes Intérêts et frais Interest and costs Dev.Lac Crystal (Magog) Inc.Weinhold, Arnold.Dev.Lac Crystal (Magog) Inc.Thibeault.Jean-Marie.Battaglia, André.Buck, Warren Carl.Firlotle, Marcel.Dev.Lac Crystal (Magog) Inc.Goudie, Georges.Tourigny, Olivier .Moulton, J.Philip .Aménagement L.N.N.Inc.Notebaert, G., Noël.Aurélien et Claude Langlois James.Arthur.Shatney, Harold .Ross.Bemice Mrs.5.000 p.c./sq.ft.7.500 p.c./sq.ft.10,000 p.c./sq.ft.7,625 p.c./sq.ft.5,000 p.c./sq.ft.8.000 p.c./sq.ft.7,500 p.c./sq.ft.7.500 p.c./sq.ft, 5 acres .3C-'/2 116 .3A-31 à/to 41 3A-55-56-57 .3A-60-1.3A-61-62 P.3A.5A-46 .3C-59.3C-68.5A-99 .P.14B.3C-72.P.I4A.3C-112.3C-102.P.9A.13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 12.60 8.40 11.20 16.80 14.00 59.40 16.80 110.60 35.64 973.79 40.37 17.02 48.58 283.53 29.45 401.62 47.50 64.31 581.78 10.21 24.26 6.71 4.68 16.23 4.60 36.17 2.45 6.29 11.73 8.83 32.55 Corporation municipale d'Ogden \u2014Municipal Corporation of Ogden Dezan, Donald (Directeur des Vétérans).Harvey, Douglas.Hibbard, Eva Mrs.Huckins, Rupert .388 .P.142 .P.613.P.613 P.617.27.00 15.00 $ 319.91 213.27 142.16 11.26\tS 358.17 2.80\t17.90 6.98\t220.25 5.01\t147.17 Corporation municipale du village d'Omerville (Bolton) \u2014Municipal Corporation of the Village d'Omerville (Bolton) Casavant.Armand .(Mme Victor Fortin) Laroche.Gilles.Vachon.Raymond .Chassé.Clément et G.Talbol Provencher.Marcel.7,500 p.c./sq.ft.10 ,500 p.c .500 p.c ,500 p.c .250 p.c ,250 p.c .250 p.c ,250 p.c .250 p.c ,625 p.c.250 p.c .250 p.c.,250 p.c ,250 p.c.,250 p.c.,250 p.c.,250 p.c./sq.ft./sq.ft./sq.ft./sq.ft./sq.ft./sq.ft./sq.ft./sq.ft./sq.ft./sq.ft./sq.ft./sq.ft./sq.ft./sq.fi./sq.ft./sq.ft.2D-3 .1-233 .2D-157 2D-172 2C-33 .3B-24.3B-25 .3B-26 .3B-27 .3B-32 .3B-33 .3B-34 .3B-35 .3B-36.3B-37 .3B-38.3B-39.20\t$ 168.50\t$ 121.38\t$ 20.83\t$ 310.71 20\t216.50\t129.92\t25.82\t372.24 20\t\t\t\t 20\t174.00\t99.17\t15.76\t288.93 19\t58.00\t9.50\t5.10\t72.60 19\t\t\t\t 19\t\t\t\t 19\t\t\t\t 19\t\t\t\t 19\t\t\t\t 19\t\t\t\t 19\t\t\t\t 19\t\t\t\t 19\t\t\t\t 19\t\t\t\t 19\t\t\t\t 19\t418.25\t\t25.00\t443.25 Municipalité de Ste-Catherine de Hatley \u2014 Municipality of St.Catherine of Hatley Beaudean Dev.Inc.Ducrée.Peter .10 acres.8.250 p.c./sq.ft.P.967 .1157-118 6\t\t$ 40.19\t$ 4.05\t$ 44.24 8\t$ 3.96\t22.05\t3.20\t29.21 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U janvier 1975, 107' année, n° 2 239 Nom des propriétaires Names of proprietors\tSuperficie Area\tLots Nos\tRang Range\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes scolaires School taxes\tIntérêts et frais Interest and costs\tTotal Griffiths, Dr.V.\t10,044 p.c./sq.ft.11.275 p.c./sq.ft.50.620 p.c./sq.ft.45,425 p.c./sq.ft.15.000 p.c./sq.ft.41.200 p.c./sq.ft.\t1144-138 .1145-4 .966-18.P.966 .P.861 .1145.1375-63 .966-7.P.966 .\t7 7 6 5 7 9 6\t23.35 58.20 14.95 46.21\t166.49 127.81 338.61 417.32 255.11 42.08 264.68\t18.42 9.60 33.97 5.62 26.15 4.33 8.65\t184.91 160.76 372.58 422.94 339.46 61.36 319.54 Corporation municipale de Stanstead-Est \u2014Municipal Corporation of Stanstead-East\t\t\t\t\t\t\t Watson, Melvin.\t170.140.\t1116.1117.\t14 14\t$ 64.00\t$ 474.52\t$ 4.84\t$ 543.36 Corporation municipale du canton de Hatley Ouest \u2014Municipal Corporation of the Township of West Hatley\t\t\t\t\t\t\t Dubé, Jean-Paul.Kydd, Charles.Smith, Hubert.\t\tP.989 .P.647 .P.90.P.973 .P.646 .P.116.P.117\t6 4 1 6 4 1\t$ 19.14 31.20 21.60 66.20 4.00\t$ 29.76 155.84 107.90 136.88 11.29 65.95\t$ 2.72 7.30 5.92 5.39 1.67 4.20\t$ 51.62 194.34 135.42 208.47 16.96 70.15 Corporation municipale du village de Hatley \u2014Municipal Corporation of the Village of Hatley \t\tP.61 .\t1\tS 20.00\t$ 46.18\t$ 2.90\t$ 69.08 Corporation municipale de St-Herménégilde \u2014Municipal Corporation of St.Herménégilde\t\t\t\t\t\t\t T.H.Vandyke Estate Inc.Gray.Dorgon .\t39,204 p.c./sq.ft.23.125 p.c./sq.ft.\t19C .P.25.\t1 1\t$ 1.95\tS 16.18\t$ 1.87\t$ 1.95 18.05 Corporation municipale de St-Herménégilde village Municipal Corporation of the Village of St.Herménégilde Jacques, S.Joseph Succ .P.28A .$ 0.64 0.64 Commission scolaire du district de Lennoxville (Rock Island) Lennoxville District School Board (Rock Island) \t\t4-121 .\t\t\t$ 169.60\t$ 6.89\t$ 176.49 \t\t4-122 .\t\t\t11.52\t.81\t12.33 \t\tP.Ill .\t\t\t349.37\t11.22\t360.59 240 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1976, Vol.107, No.2 Corporation municipale du canton de Hatley \u2014 Municipal Corporation of the Township of Hatley Nom des propriétaires Names of proprietors\tSuperficie Area\tLots Nos\tRang Range\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes scolaires School taxes\tIntérêts et frais Interest and costs\tTotal Yuile, Robert.La Chevrière Inc.\t\t640-47 .135, 136.137.272.273.382 .\t\t\t$ 207.06 1.263.88\t$ 8.30 106.75\t$ 215.30 1,370.63 Corporation municipale du village de North Hatley \u2014Municipal Corporation of the Village of North Hatley\t\t\t\t\t\t\t Bourgoin, Gérard .Laberge.Jacques (Hotel Pleasant View) .\t\t523-11 .523-12 .530.531 .P.516.P.523 .\t\t$ 7.85 220.68 231.19 3.464.47\t$ 10.60 223.40 198.46 4,989.31\t$ 1.43 36.06 36.32 870.89\t$ 19.88 480.14 465.97 9,324.67 Corporation municipale Barnston Ouest \u2014Municipal Corporation of Banrston West\t\t\t\t\t\t\t Aldrich.Frank.Distefano, Francis e\\AI.Langlois.Roger .Przytyk.Jerzy et Chaimowicz .Savage.Michel et Uxor.\t.08.55 x 105 .25.26.35.\tP.4F.P.3A.P.9A .P.2C et P.2D .P.9B.\t5 11 6 6 3\t$ 0.51 3.84 3.79 9.33\t$ 164.38\tS .09 1.06 2.72 2.11 6.50\t$ 0.60 4.90 6.51 11.44 170.88 Toutes les surfaces ou autres dimensions indiquées ci-dessus sont données plus ou moins.Donné et daté à Magog, P.Que., ce 30e jour de décembre 1974.Le secrétaire-trésorier, 59564-0 Jean-Paul Asselin.Municipalité du comté de Québec Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Adélard L'Heureux, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Québec, que les immeubles ci-après décrits seront vendus à l'enchère publique, au Centre Paroissial de Loretteville, lieu où ic conseil municipal dudit comté tient ses sessions, JEUDI, le TREIZIÈME jour du mois de MARS 1975, à DIX heures de l'avant-midi, pour défaut de paiement des taxes municipales et scolaires et autres charges dues aux corporations locales ci-après nommées, à moins que lesdites taxes avec les frais ne soient payés avant la vente.Corporation municipale de St-Félix-de-Cap-Rouge Comme appartenant à M.Hubert Dansereau: Le lot connu et désigné sous le numéro (2-1) un de la subdivision du lot originaire deux du cadastre officiel Ail surface of other dimensions hereinabove indicated are more of less.Given and dated at Magog, P.Que., this 30th day of December 1974.Jean-Paul Asselin, 59564 Secretary-Treasurer.Municipality of the County of Québec Public notice is hereby given by the undersigned, Adélard L'Heureux, Secretary-Treasurer of the Corporation of the County of Québec, that the immoveables hereinafter described will be sold by public auction at the Centre Paroissial of Loretteville, where the sittings of the Municipal Council of the said County are held, THURSDAY, on the THIRTHIETH day of the month of MARCH 1975, at TEN o'clock in the forenoon, for default of payement of municipal and school taxes and other charges due to the local corporations hereinafter mentioned, unless the said taxes and costs be paid before the sale.Municipal Corporation of St-Félix-de-Cap-Rouge As belonging to Mr.Hubert Dansereau : The lot known and designated under number (2-1) one of the subdivision of the original lot two of the GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n\" 2 241 de la paroisse de St-Félix-de-Cap-Rouge, division d'enregistrement de Québec, circonstances et dépendances.Taxes municipales: 81,700.35, taxes scolaires: 82,605.35.Total: 84,305.70.Comme appartenant à The Suburban Realty Co.Inc.: Les lots connus et désignés sous les numéros (19-66, -67, -68, -69, r70, -71, -72, -73, -74, -75, -76.-77, -78), soixante-six.soixante-sept, soixante-huit, soixante-neuf, soixante-dix, soixante et onze, soixante-douze, soixante-treize, soixante-quatorze, soixante-quinze, soixante-seize, soixante-dix-sept, soixante-dix-huit, de la subdivision du lot originaire dix-neuf du cadastre officiel de la paroisse de St-Félix-de-Cap-Rouge, division d'enregistrement de Québec, circonstances et dépendances.Taxes municipales : S407.57, taxes scolaires : 81,146.63.Total: 81.554.20.Comme appartenant à The Suburban Realty Co.Inc.: Les lots connus et désignés sous les numéros (19-124) cent vingt-quatre de la subdivision du lot originaire dix-neuf et (22-39) trente-neuf de la subdivision du lot originaire vingt-deux du cadastre officiel de la paroisse de St-Félix-de-Cap-Rouge, division d'enregistrement de Québec, circonstances et dépendances.Taxes municipales: 8281.84, taxes scolaires: 895.29.Total: 8377.13.Comme appartenant à The Suburban Realty Co.Inc.: Le lot connu et désigné sous le numéro (22-86) quatre-vingt-six de la subdivision du lot originaire vingt-deux du cadastre officiel de la paroisse de St-Félix-dc-Cap-Rouge, division d'enregistrement de Québec, circonstances et dépendances.Taxes municipales: 8204.27, taxes scolaires: $133.61.Total: $337.88.Comme appartenant à Succession Agnes Lewis: Le lot connu et désigné sous le numéro (22-100-101) cent et cent un de la subdivision du lot originaire vingt-deux du cadastre officiel de la paroisse de St-Félix-de-Cap-Rougc, division d'enregistrement de Québec, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $274.18, taxes scolaires: $111.33.Total: $385.51.Comme appartenant à William Lambton: Les lots connus et désignés sous les numéros (18-45) quarante-cinq de la subdivision du lot originaire dix-huit, (19-165) cent soixante-cinq de la subdivision du lot originaire dix-neuf et (19-166) cent soixante-six de la subdivision du lot originaire dix-neuf du cadastre officiel de la paroisse de St-Félix-de-Cap-Rouge, division d'enregistrement de Québec, circonstances et dépendances.Taxes municipales: 820.99.taxes scolaires: $45.58.Total: $66.57.officiai cadastre for the Parish of St-Félix-de-Cap-Rouge, Registry Office of Québec, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $1,700.35, school taxes: 82,605.35 Total : $4,305.70.As belonging to The Suburban Realty Co.Inc.: The lots known and designated under number (19-66, -67, -68, -69, -70, -71, -72, -73, -74, -75, -76, -77, -78) sixty-six, sixty-seven, sixty-eight, sixty-nine, seventy, seventy-one, seventy-two, seventy-three, seventy-four, seventy-five, seventy-six, seventy-seven, seventy-eight, of the subdivision of original lot nineteen of the official cadastre for the Parish of St-Félix-de-Cap-Rouge.Registry Office of Québec, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $407.57, school taxes: $1,146.63.Total: $1,554.20.As belonging to The Suburban Realty Co.Inc.: The lots known and designated under number (19-124) one hundred and twenty-four of the subdivision of the original lot nineteen and (22-39) thirty-nine of the subdivision of the original lot twenty-two of the official cadastre for the Parish of St-Félix-de-Cap-Rouge, Registry Office of Québec, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $281.84, school taxes: $95.29.Total: 8377.13.As belonging to The Suburban Realty Co.Inc.: The lot known and designated under number (22-86) eighty-six of the subdivision of the original lot twenty-two of the official cadastre for the Parish of St-Félix-de-Cap-Rouge, Registry Office of Québec, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $204.27, school taxes: 8133.61.Total: $337.88.As belonging to Succession Agnes Lewis: The lot known and designated under number (22-100-101) one hundred and one hundred and one of the subdivision of original lot twenty-two of the official cadastre of the Parish of St-Félix-de-Cap-Rouge, Registry Office of Québec, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $274.18, school taxes: 8111.33.Total: 8385.51.As belonging to Mr.William Lambton: The lots known and designated under number (18-45) forty-five of the subdivision of the original lot eighteen, (19-165) one hundred and sixty-five of the subdivision of original lot nineteen and (19-166) one hundred and sixty-six of the subdivision of original lot nineteen of the official cadastre for the Parish of St-Félix-de-Cap-Rouge, Registry Office cf Québec, circumstances and dependencies.Municipal taxes: 820.99, school taxes: $45.58.Total: 866.57. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.S 242 Comme appartenant à M.Richard Tremblay: Le lot connu et désigné sous le numéro (65) soixante-cinq du cadastre officiel de la paroisse de St-Félix-de-Cap-Rouge, division d'enregistrement de Québec, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $166.09, taxes scolaires: $76.43.Total: $242.52.Comme appartenant à M.Raoul Tremblay: Le lot connu et désigné sous le numéro (66) soixante-six du cadastre officiel de la paroisse de St-Félix-de-Cap-Rouge, division d'enregistrement de Québec, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $168.00, taxes scolaires: $80.27.Total: $248.27.Comme appartenant à M.Georges L.Demers: Le lot connu et désigné sous le numéro (19-62,-65,-108) soixante-deux, soixante-cinq, cent-huit de la subdivision du lot originaire dix-neuf du cadastre officiel de la paroisse de St-Félix-de-Cap-Rouge, division d'enregistrement de Québec, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $63.10, taxes scolaires: $108.66.Total: $171.76.Corporation municipale de Ste-Thérèse-de-Lisieux Comme appartenant à M.Jean-Guy Chassé: Les lots connus et désignés sous les numéros (1544-10 et -11) dix, onze de la suvdivision du lot originaire quinze cent quarante-quatre du cadastre officiel de la paroisse de Beauport, division d'enregistrement de Québec, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $1,105.60, taxes scolaires: $527.44.Total: $1,633.04.Comme appartenant à M.Roland Légaré: Partie du lot numéro (901 n.s.) neuf cent un non subdivisé du cadastre officiel de la paroisse de Beauport, division d'enregistrement de Québec, mesurant 150 pieds de largeur par 150 pieds de profondeur, (environ).Bornée à l'est par le boul.Raymond, au nord par la rue St-Ignace, au sud et à l'ouest par l'autre partie du lot 901, le tout représentant une superficie de 22,500 p.c, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $206.31, taxes scolaires: $290.56.Total: $496.87.Corporation municipale du Lac St-Charles Comme appartenant à Succession M.Louis Lavoie'.Le lot connu et désigné sous le numéro (1454-1) un île la subdivision du lot originaire mille quatre cent cinquante-quatre du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, division d'enregistrement de Québec, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $577.97, taxes scolaires: $1,593.97.As belonging to Mr.Richard Tremblay: The lot known and designated under number (65) sixty-five of the official cadastre for the Parish of St-Félix-de-Cap-Rouge, Registry Office of Québec, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $166.09, school taxes: $76.43.Total: 8242.52.As belonging to Mr.Raoul Tremblay : The lot known and designated under number (66) sixty-six of the official cadastre for the Parish of St-Félix-de-Cap-Rouge, Registry Office of Québec, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $168.00, school taxes: $80.27.Total: $248.27.As belonging to Mr.Georges L.Demers: The lot known and designated under number (19-62, -65, -108) sixty-two, sixty-five, one hundred and eight of the original lot nineteen of the official cadastre for the Parish of St-Félix-de-Cap-Rouge, Registry Office of Québec, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $63.10, school taxes: $108.66.Total: $171.76.Municipal Corporation of Ste-Thérèse-de-Lisieux As belonging to Mr.Jean-Guy Chassé: The lots known and designated under number (1544-10 and -11) ten, eleven of the subdivision of original lot one thousand five hundred and fourty-four of the official cadastre for the Parish of Beauport, Registry Office of Québec, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $1,105.60, school taxes: $527.44.Total: $1,633.04.As belonging to Mr.Roland Légaré: Part of lot number (901 n.s.) nine hundred and one undivided part of the official cadastre for the Parish of Beauport, Registry Office of Québec, measuring 150 feet in width by 150 feet in depth, (about).Bounded to the east by the Raymond Blvd., to the north by the St-Ignace Street, to the south and to the west by other part of the lot 901 the whole representing an area of 22,500 sq.ft., circumstances and dependencies.Municipal taxes: $206.31, school taxes: $290.56.Total: $496.87.Municipal Corporation of Lac St-Charles As belonging to Succession Mr.Louis Lavoie: The lot known and designated under number (1454-1) one of the subdivision of the original lot one thousand four hundred and fifty-four of the official cadastre for the Parish of St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Registry Office of Québec, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $577.97, school taxes: $1,593.97. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' aimée, n° J 243 Comme appartenant à M.Roland O.Rliéaumc: Partie du lot numéro (1358) mille trois c.*nt cinquante-huit du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeunc-l.orette, division d'enregistrement de Québec.Bornée vers le nord-est par la Première Avenue, vers le nord-ouest par le lot 1359, vers le sud-ouest par, le résidu du lot 1358, avec bâtisses dessus construites circonstances et dépendances.Taxes municipales: $613.50.taxes scolaires: SI,030.72.Comme appartenant à M.Hervey Huot: Paitie des lots numéros (1330) mille trois cent trente et (1331) mille trois cent trente et un du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise-de-la-.Toune-Lorette, division d'enregistrement de Québec.Bornée au sud-est par la rue Villeneuve, ver» le sud-ouest par partie des mêmes lots appartenant à M.Roger Berthiaume, vers le nord-ouest par la rivière St-Charles, vers le nord-est par partie des mêmes lots appartenant à M.Jacques, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $92.51, taxes scolaires: $159.68._ Comme appartenant à Mme Fernande Blouin Emond : Les lots minières (1330-14) quatorze de la subdivision du lot mille trois cent trente et (1331-30) trente de la subdivision du lot mille trois cent trente et un du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, division d'enregistrement de Québec, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $308.30.Comme appartenant à M.Claude Houdc: Le lot numéro (1301-3) trois de la subdivisit n du lot mille trois cent un du cadastre officiel de la paioisse de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, division d'enregistrement de Québec, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $504.58, taxes scolaires: $220.73.Comme appartenant à M.Fernand Beaulieu: Le lot numéro (1300-2) deux de la subdivision du lot originaire mille trois cent du cadastre officiel île la paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette.division d'enregistrement de Québec, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $763.48.Comme appartenant à M.Marc Pelchat: Le lot numéro (1301) mille trois cent un du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise-de-la-.Jcune-Lorette, division d'enregistiement de Québec, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $25.55, taxes scolaires: $42.41.Comme appartenant à Mme Marie-Jeanne Rhéaume: Partie du lot numéro (1392) treize cent quatre-vingt-douze du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, division d'enregistrement de Québec, mesurant approximativement 35 pieds dans ses lignes nord-est et sud-ouest sur 45 pieds de profondeur dans ses lignes nord-ouest et sud-est.mesure anglaise.As belonging to Mi.Roland O.Rhéaume: Part of lot number (1358) one thousand three hundred and fifty-eight of the official cadastre for the Parish of St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Registry Office of Québec.Bounded to the northeast by the First Avenue, to the northwest by the lot 1359, to the southwest by the residue of the lot 1358, with buildings thereon erected, circumstance sand dependencies.Municipal taxes: $613.50, school taxes: $1,030.72.As belonging to Mr.Hervey Huot: Part of lots number (1330) one thousand tluee hundred and thirty and (1331) one thousand three hundred and thirty-one of the official cadastre for the Parish of St-Ambroise-de-la-.Ieune-Lorette, Registry Office of Québec.Bounded to the southeast by the Villeneuve Street, to the southwest by part of the same lots belonging to Mr.Roger Berthiaume, to the northwest by the Rivière St-Charles, to the northeast by part of the same lots belonging to Mr.Jacques, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $92.51, school taxes: $159.68.As belonging to Mrs.Fernande Blouin Émond: The lots numbers (1330-14) fourteen of the subdivision of lot one thousand three hundred and thirty and (1331-30) thirty of the subdivision of lot one thousand three hundred and thirty-one of the official cadastre for the Parish of St-Ambroise-de-la-Jeunc-Lorette, Registry Office cf Québec, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $308.30.As belonging to Mr.Claude Houde: The lot number (1301-3) three of the subdivision of lot one thousand three hundred and one of the official cadastre for the Parish of St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorctte, Registry Office of Québec, with buildings thereon erected, ciicumstances and dependencies.Municipal taxes: $504.58, school taxes: $220.73.As belonging to Mr.Fernand Heaulieu: The lot number (1300-2) two of the subdivision of the original lot one thousand three hundred of the official cadastre for the Parish of St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Registry Office of Québec, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $763.48.As belonging to Mr.Marc Pelchat: The lot number (1301) one thousand three hundred and one of the official cadastre for the parish of St-Ambroise-de-la-Jeune-Ixirette, Registry Office of Quebec, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $25.55, school taxes: $42.41.As belonging to Mrs.Marie-Jeanne Rhéaume: Part of lot number (1392) one thousand three hundred and ninety-two of the official cadastre for the Parish of St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette.Registry Office of Québec, measuring approximately 35 feet in its northeast and southwest lines on 45 feet in depth in its northwest and southeast linos.English measure. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January U, 1975, Vol.107, No.S Bornée vers le nord-ouest par le terrain de Ovide Rhéaume, vers le nord-est et le sud-est par celui de Gaétan Leblanc, vers le sud-ouest par Roger Chouinard, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $513.49, taxes scolaires: $228.12.Comme appartenant à M.Robert Simard et al: Partie du lot numéro (1274) douze cent soixante-quatorze du cadastre officiel de la paroisse de St-Am-broise-de-la-.Ieune-Lorette, division d'enregistrement de Québec.Bornée vers le nord-est par la Première Avenue, vers le nord-ouest par la rivière St-Charles, vers le sud-est par un chemin privé, vers le sud-ouest par le résidu du même lot appai tenant à un tiers, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Taxes municipales: $1,636.99.Donné à Loretteville, ce deuxième jour du mois de janvier mil neuf cent soixante-quinze.Le secrétaire-trésorier, C.M.C.Q.59567-2-2-0 Me Robert L'Heureux, notaire.Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.HULL Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Hull l T A CAISSE POPULAIRE DU SA-No 91,353.{ ¦L' CRÉ-COEUR DE HULL, corpo-l ration légalement constituée ayant sa place d'affaires à Hull, province de Québec, demanderesse, vs M.GUY BOYÉR, domicilié et résidant sur le Chemin des Érables, à Limbour, province de Québec, défendeur.1° « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 101, de la subdivision officielle du lot numéro six (6-101), Rang 8, Canton de Hull; » 2° « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 33, de la subdivision officielle du lot numéro six (6-33), Rang 8, Canton de Hull.» Pour être vendus « Séparément » au bureau d'enregistrement de la division de Gatineau.à Maniwaki.P.Q.le QUATORZIÈME jour de FÉVRIER, 1975, à DEUX heures de l'après-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Jean-Guy Rochon.District de Hull, P.Q., ce 18 décembre 1974.59539-0 Bounded to the northwest by the piece of land of Ovide Rhéaume, to the northeast and to the southeast by Gaétan Leblanc, to the southwest by Roger Chouinard, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $513.49, school taxes: $228.12.As belonging to Mr.Robert Simard et al: Part of lot number (1274) one thousand two hundred and seventy-four of the official cadastre for the Parish of St-Ambroise-de-la-Jeune-Loiette, Registry Office of Québec.Bounded to the northeast by the First Avenue, to the northwest by the Rivière St-Charles, to the southeast by a private road, to the southwest by the residue of the same lot belonging to a third, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $1,636.99.Given at Loretteville, this second day of the month of January one thousand nine hundred and seventy-five.Me Robert L'Heureux, Notary, 59567-2-2-0 Secretary-Treasurer, C.M.C.Q.Sheriffs Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.HULL Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Hull l T A CAISSE POPULAIRE DU SA-No.91,353.< J-' CRÉ-COEUR DE HULL, a cor-' poration legally incorporated, having its place of business in Hull, Province of Québec, plaintiff, vs MR GUY BOYER, domiciled and residing on Chemin des Érables, in Limbour, Province of Québec, defendant.1.\"An immoveable known and described as being lot number 101.of the official subdivision of lot number six (6-101).in Range 8, Township of Hull;\" 2.\"An immoveable known and described as being lot number 33, of the official subdivision of lot number six (6-33), in Range 8, Township of Hull.\" To be sold separately, at the Gatineau division registry office, in Maniwaki, P.Q., on the FOURTEENTH day of FEBRUARY, 1975, at TWO o'clock in the afternoon.Jean-Guy Rochon, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.District of Hull, P.Q., December 18, 1974.59539 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il janvier 1975, 107' année, n° 2 245 JOLIETTE Fieri Facias De Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Montréal f T At'RENTIDE ACCEPT-No 02-411500-7IX *-> ANCE CORPORATION LIMITED, corporation légalement constituée ayant son siège social et/ou sa principale place d'affaires au 7788 est, rue Sherbrooke, Montréal, district de Montréal, partie demanderesse, vs ALEXANDRE & ALDEA_ LECOMFrE, tous deux domiciliés et résidant au 1579 rue Holmes.St-Hubert, district de Montréal, partie défenderesse.« Un terrain extrait du lot No 35 (P.35) du septième Rang du Canton de Cathcart, on la paroisse de St-Côme.comté de Joliette, mesurant environ cent dix pieds (110') de largeur sur cent vingt-cinq (125') de profondeur, mesure anglaise et borné comme suit: A un haut par un lac artificiel communément appelé « Lac aux Oiseaux », en profondeur par une autre partie dudit lot No 35 appartenant à M.Wilfrid Lepage, d'un côté par le terrain de Chs.Emile Hamel (Enrg.119512) et de l'autre côté par le terrain de Gérard Messier (Enrg.118628) avec y érigé, un camp d'été, et tout ce qui s'y trouve présentement.» Pour être vendu au bureau de la division d'enregistrement de Joliette, 577 rue Notre-Dame, Joliette, district de Joliette, JEUDI, le TREIZIÈME jour de FÉVRIER 1975, à ONZE heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du shérif, Ginette Malo.Joliette, le 19 décembre 1974.59574-0 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Joliette (OOCIÉTÉ CENTRALE No 705-05-000472-74X O D'HYPOTHÈQUES ET v.DE LOGEMENT, corporation légalement constituée en vertu d'une loi spéciale du parlement canadien, ayant son siège social en la cité d'Ottawa, agissant aux fins des présentes sous l'autorité de l'article 40 de la loi de 1954 sur l'habitation, contenu dans les statuts du Canada, partie demanderesse, vs ANGELO FIORENTU, comptable, domicilié au No 1626 rue Selkirk, dans la cité et le district de Montréal, partie défenderesse, et ALAIN RIVEST, constructeur, domicilié au 698 rue Notre-Dame, dans la cité de Repen-tigny, district de Joliette, et DAME ANGELO FIO-RENTU-ONGARO, domiciliée au 55 rue Bcllefeuille en la municipalité de Rcpenligny, district de Joliette et GAETAN GIGUÈRE, en sa qualité de régistrateur pour la division d'enregistrement de L'Assomption, mis en cause.JOLIETTE Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Montreal I T AURENTIDE ACCEPT-No.02-411500-71.-J *-> ANCE CORPORATION \\ LIMITED, a corporation legally incorporated, having its head office and/or its principal place of business at 7788 Sherbrooke Street East, Montreal, District of Montreal, plaintiff, versus ALEXANDRE AND ALDEA LECOMPTE, both domiciled and residing at 1579 Holmes Street, Saint-Hubert, District of Montreal, defendants.\"A piece of land taken from lot number 35 (Pt.35) in the seventh Range of the Township of Cathcart, in the Parish of Saint-Côme, County of Joliette, measuring approximately one hundred and ten feet (110') in width by one hundred twenty-five feet (125') in depth, English measure and bounded as follows: At one end by an artificial lake commonly called \"Lac aux Oiseaux\", on its depth by another part of the said lot number 35 belonging to Mr.Wilfrid Lepage, on one side by the land belonging to Chs.Emile Hamel (Reg.119512) and on other side by the land belonging to Gérard Messier (Reg.118628), with a summer cottage erected thereon, including all its present content.\" To be sold at the Joliette Registration Division Office, 577 Notre-Dame Street, Joliette, District of Joliette, on THURSDAY, the THIRTEENTH dav of FEBRUARY, 1975, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Ginette Malo, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Joliette, December 19, 1974.59574 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Joliette ( f\"«ENTRAI MORTGAGE No.705-05-O00472-74X v-i AND HOUSING COR- l PORATION, a corporation legally incorporated under a special law of the Parliament of Canada, having its head office in the City of Ottawa, hereby acting under the authority of section 40 of the Housing Act of 1954, included in the Statutes of Canada, plaintiff, vs ANGELO FIORENTU, accountant, domiciled at 1626 Selkirk Street, in the City and District of Montreal, defendant, and ALAIN RIVEST.builder, domiciled at 698 Notre-Dame Street, in the Town of Repentigny, District of Joliette, and MRS.ANGELO FIORENTU-ONGARO.domiciled at 55 Bellefeuille Street, in the Municipality of Repentigny, District of Joliette, and GAETAN GÏGUÈRE, in his capacity as registrar for L'Assomption registration division, mis en cause. 246 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January U, 1975, Vol.107, No.S « Un emplacement situé à Repentigny, comté de L'Assomption, connu et désigné comme étant le lot No quatre-vingt-quatre de la subdivision officielle du lot originaire quarante-six (46-84) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse Notre-Dame de L'Assomption de Repentigny.Avec la bâtisse dessus érigée.Tel que le tout se trouve présentement, avec servitudes actives et passives, attachées audit emplacement.» Pour être vendu à L'Assomption, au bureau de la division d'enregistrement de L'Assomption, 255 rue St-Étienne.district de Joliette, MARDI, le DIX-HUITIÈME jour de FÉVRIER 1975, à ONZE heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du shérif, Ginette Malo.Joliette, le 27 décembre 1974.59575-o MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal l TNAME MADELEINE AUDET.No 05-013672-73A ^ veuve de Jules Gontliier et ' épouse séparée de biens de Fabien Bélanger, résidant et domiciliée au 125 avenue Hand-field, dans la ville de Laval, district de Montréal, demanderesse, vs MAURICE C.LANIEL, résidant et domicilié au 3465, avenue Belmore, dans les ville et district de Montréal, défendeur.« Un emplacement situé en la cité de Montréal, ayant front sur l'avenue Belmore, et composé du lot numéro trente-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quarante-sept (147-38) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Montréal.Avec maison dessus érigée, portant le numéro civique 3465 de ladite avenue Belmore, en la cité de Montréal.Tel que le tout se trouve présentement, avec servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit emplacement.» Pour être vendu au bureau du Shérif, au Palais de Justice, en la ville de Montréal, 10 est, rue Craig.10e étage, chambre 56, le ONZIÈME jour de FÉVRIER 1975, à ONZE heures a.m.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure.Paul St-Martin.Montréal, le 3 janvier 1975.59557-0 SAINT-HYACINTHE Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de St-Hyacinthe t T IONEL ROBERT, dcnian-No 750-02-000519-74X ^ deur-saisissant, vs JULES-l ANDRÉ DONAIS, défendeur-saisi, tu LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Rouville, mis en cause.\"An emplacement located in Repentigny, County of L'Assomption, known and described as being lot number eighty-four of the official subdivision of original lot forty-six (46-84) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Notre-Dame-de-L'Assomp-tion, of Repentigny.With the building erected thereon.As the whole now subsists, with all active and passive servitudes attaching to said emplacement.\" To be sold in L'Assomption, at the Office of L'As-somption Registration Division.255 Saint-Étienne Street, District of Joliette, on TUESDAY, the EIGHTEENTH day of FEBRUARY, 1975, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Ginette Malo, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Joliette, December 27, 1974.59575 MONTREAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( \\/TRS.MADELEINE AUDET, No.05-013672-73.-) widow of Jules Gonthier » and wife, separate as to property of Fabien Bélanger, residing and domiciled at 215 Hand-field Avenue, in the City of Laval.District of Montreal, plaintiff, vs MAURICE C.LANIEL, residing and domiciled at 3465 Belmore Avenue, in the City and District of Montreal, defendant.\"An emplacement located in the City of Montreal, fronting on Belmore Avenue, and comprising lot number thirty-eight of the official subdivision of original lot number one hundred forty-seven (147-38) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Montreal.With the house erected thereon, bearing civic number 3465 of said Belmore Avenue, in the City of Montreal.As the whole now subsists, with all active and passive, apparent or non apparent servitudes attaching to said emplacement.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the City of Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56.on the ELEVENTH day of FEBRUARY 1975, at ELEVEN o'clock a.m.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 3, 1975.59557-0 SAINT-HYACINTHE Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Saint-Hyacinthe ( T IONEL ROBERT, dis-No.750-02-000519-74.4 *-> training plaintiff, vs l JULES-ANDRÉ DONAIS, distrained defendant, vs THE REGISTRAR for the Rouville Registration Division, mis en cause. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° 2 247 « Un immeuble situé à St-Hilaire, connu et désigné comme étant les lots numéros quarante-sept subdivision un (47-1), trente-huit subdivision six (38-6) et trente-huit subdivision P-sept (38-P7) du cadastre de la paroisse de St-Hilaire, pour une superficie totale de onze mille six cent trente-deux pieds carrés (11,632 p.c), avec les bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances, portant les numéros civiques 290, 292 et 294 de la rue St-Hippolyte, Saint-Hilaire, district de St-Hyacinthe.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement, division de Rouville, à Maiïevillc comté de Rouville, MERCREDI, le CINQUIÈME jour de MARS 1975, à DEUX heures de l'après-midi.Saint-Hyacinthe, 30 décembre 1974.Le shérif, Michel Laroche.District de Saint-Hyacinthe.59565-u TÉMISCAMINGUE Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Rouyn-Noranda ( \"DRANK P.TAGLIAMONTE.ingé-No 324-74.\\ L nieur professionnel, résidant et v ayant son domicile à 134, 19e rue, No-randa, P.Q.demandeur, vs RAYDAN MINING COMPANY LIMITED, une corporation ayant un bureau à Belleterre, P.Q.défenderesse.« Tous les droits miniîrs appartenant à la défenderesse dans la propriété minière suivante, à savoir: huit (8) claims miniers étant les numéros 267553, daims 3 el 5; 267552.claim 4; 267555.claims 1 et 2; 325870, claims 1, 2 et 3 avec tous les droits et avantages accessoires appartenant à la défenderesse en rapport avec lesdits propriétés minières incluant les crédits à échoir à la défenderesse suivant la loi chez le département de Resources naturelles pour forage à diamant et autres travaux de mise en valeur fait sur lesdits claims jusqu'à la date de leur vente judiciaire.» À être vendu en bloc au bureau d'enregistrement de la division de Témiscamingue.à Ville-Marie.P.Q.le QUATORZIÈME jour de FÉVRIER, 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif.Palais de Justice.LP.Hallee.Ville-Marie, P.Q.59532-o \"An immoveable located in Saint-Hilaire, known and described as being lots numbers forty-seven, subdivision one (47-1), thirty-eight, subdivision six (38-6) and thirty-eight, subdivision P-scven (3S-P7) on the cadastre for the Parish of Sainl-Hilaire.covering a total area of eleven thousand six hundred thirty-two square feet (11,632 sq.ft.), with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, bearing civic numbers 290, 292 and 294 on Saint-Hippolyte Street, Saint-Hilaire, District of Saint-Hyacinthe.\" To be sold at the Rouville Division Registry Office, in Marieville, Countv of Rouville, on WEDNESDAY, the FIFTH day of MARCH, 1975, at TWO o'clock in the afternoon.Saint-Hyacinthe, December 30, 1974.Michel Laroche, Sheriff.District of Saint-Hyacinthe.59565 TÉMISCAMINGUE Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Rouvn Noranda / -RRANK P.TAGLIAMONTE.pro-No.324-74.\\ L fessional engineer, residing and v having his domicile at I34-I9th Street in the City of Noranda, P.Q., plaintiff, vs RAYDAN MINING COMPANY LIMITED, a corporation having an office at Belleterre, P.Q., defendant.\"All the mining rights belonging to the defendant in the following mining property namely: eight (8) mining claims, being numbers 267553, claims 3 and 5, 267552 claim 4; 267555.claims 1 and 2; 325870, claims 1, 2 and 3 with all the accesory rights and advantages belonging to the defendant relating to the said mining properties, including the credits accruing to the defendant by law with the Québec Department of Natural Resources for diamond drilling and exploration work done on the said claims up to the date of the judicial sale thereof.\" To be sold as a whole at the division of Témiscamingue reg istrv office, Ville-Marie, P.Q.on the FOURTEENTH day of FEBRUARY, 1975, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, J.P.Hallee, Court House, Sheriff.Villc-Marie, P.Q.59532-0 248 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January U, 1975, Vol.107, No.S Errata GESTIMMOBILE LTEE Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis de lettres patentes, en date du 8 novembre 1974, de la compagnie « GESTIMOBILE LTEE », paru le 7 décembre 1974 à la page 9113 du numéro 49, de la Gazette officielle du Québec, en y remplaçant dans ledit nom le mot « GESTIMOBILE » par « GESTIMMOBILE » de manière que le nom se lise ainsi: « GESTIMMOBILE LTEE ».Le directetir du service des compagnies, Pierre Desjardins.59509-o 1360-1729 L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OEUFS PROGRESSIFS DU QUEBEC Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis d'abandon de charte de la corporation « ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OEUFS PROGRESSIFS DU QUEBEC », paru le 23 novembre 1974 à la page 8820 du numéro 47 de la Gazette officielle du Québec, en y remplaçant dans ledit nom le mot «ASSOCIATION » par « L'ASSOCIATION », de manière que le nom se lise ainsi: « L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OEUFS PROGRESSIFS DU QUEBEC ».Le directeur du service des companies, Pierre Desjardins.59509-o 178-70 Errata GESTIMMOBILE LTEE Notice is given that, under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice of letters patent, dated November 8, 1974, of \"GESTIMOBILE LTEE\", published on December 7.1974 on page 9113 of issue number 49 of the Québec Official Gazette, by replacing therein, in said company's name, the word \"GESTIMOBILE\" by \"GESTIMMOBILE\", in order that said name read as follows: \"GESTIMMOBILE LTEE\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.59509-o 1360-1729 L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OEUFS PROGRESSIFS DU QUEBEC Notice is given that, under Part III of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice of surrender of charter of \"ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OEUFS PROGRESSIFS DU QUEBEC\", published on November 23, 1974 on page 8820 of issue number 47 of the Québec Official Gazette, by replacing therein in said company's name the word \"ASSOCIATION\" by \"L'ASSOCIATION\", in order that said name read as follows: \"L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OEUFS PROGRESSIFS DU QUEBEC\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.59509 178-70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° S 249 INDEX >o 2 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Chapelry of Saint-Nil de Matane (Suppression).200 Desserte de Saint-Nil de Matane (Suppression).200 Dynamic Mining Exploration Ltd.(N.P.L.) (L.P.S.).201 Estate of Roger Marquis (Benefit of Inventory).200 Exploration minière Dynamique ltée (L.R.P.) (S.L.P.).201 Fondation Lucie Bruno (L.P.) (Correction).201 Parish of Saint-Fidèle de Restigouche (Suppression).200 Paroisse de Saint-Fidèle de Restigouche (Suppression).200 Pension Fund and Program of Mouton Processors Union Employees (Régime supplémentaire de rentes en tutelle \u2014 Supplemental Pension Plan under Trusteeship).200 Succession Roger Marquis (Bénéfice d'inventaire).200 CHANGEMENT DE NOM Accordés: Loi du CHANGE OF NAME ACT Granted: Alarie, Marie Hélène Line.117 Appleton, Dione.117 Brettshaw, Dyanne.118 Broeker, Peter William.118 Chajes, George.118 Juliani, Michel Renier.118 Laverdière, Joseph Georges Henri Martial.118 Laverdière, Joseph Louis Marie.118 Paré, Joseph Alphonse Raynald.119 Pépin, Marie Élaine Louise Claudette Stéphanie.119 Demandes: Applications: Desjardins Picard, Marie, Thérèse, Murielle, Bérangère.119 Dujka, Edward.120 Krystoi Stoinistonoi, Marie.119 Loyer, Omer.119 COMMISSIONS COMMISSIONS Québec Transport Commission Commission des transports du Québec Avis de la Commission « proprio motu ».177 Avis de décisions rendues.179 Avis de décisions rendues (Erratum).186 Avis d'introduction de requêtes.123 Notice \"proprio motu\" by the Commission 177 Notice of decisions rendered.179 Notice of decisions rendered (Erratum).186 Notice of submission of applications.123 COMPAGNIES \u2014 LOI DES Abandon de charte COMPANIES ACT Surrender of Charter Ajusteurs de l'Est ltée.93 Alimentation Simard ltée.93 Association des mécanos de La Mauricie inc.93 Association des producteurs d'oeufs progressifs du Québec (L') (Correction).248 Assurances P.Louis Lepage ltée.93 Beverly Corporation.93 Bolduc (Paul) inc.93 Bouesnard (Jacques) Ltd.93 Bureau d'aménagement touristique des Schick- Schocks inc.93 Central Purchasing Corporation (1955).93 Dawson Investment Corp.93 Décaiie construction ltée-Ltd.93 Distribution Vimont inc.93 Eastern Adjusters Ltd.93 Entreprises Roberval, ltée (Les).94 Hôpital général de Joliette.93 L & W Realties Ltd.93 Mahon (Thomas J.), Limited.93 Montreuil (Gaétan) inc.93 Muscoot Limited.93 Oeuvre des loisirs de la S.S.J.B.de Rivière Blanche inc.93 Parks (Harry E.) Limited.94 Pavage Régional inc.94 Ramsay's Express Moving & Storage Ltd.94 Regional Paving Inc.94 250 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 11, 1975, Vol.107, No.2 Abandon Surrender de charte of Charter (suite) (continued) Roberval Enterprises Ltd.94 Rosita Hosiery Mills Ltd.94 Someco Colbert Inc.94 Taverne Radisson inc.94 Vanix Inc.94 Administrateurs Directors (Article 84) (Section 81) Abitibi Truck Line Limited.101 Boreal Hydraulic Equipment Inc.102 C.S.S.Communication Sales and Service Inc.102 Carrière (Marc) limitée.101 Central Truck Lines Ltd.101 Cliamplain Sept-Iles Express Inc.101 Champlain Sept-Iles Express Inc.102 Cherry River Chalets Inc.102 Contact Inc.\u2022\u2022\u2022 102 Communication ventes et service C.S.S.inc.102 Compagnie financière européenne ltée (La).102 Dumont Express ltée.102 Dumont inc._.102 Equipement hydraulique Boréal inc.102 European Financial Company Ltd.102 Immeubles Val-Martin ltée (Les).102 Jardins Versailles inc.102 Matéconomie ltée.102 Meunier (Jean-Marie) inc.102 Montreal Symphony Orchestra.102 Norm (A.A.) & Co.Ltd.102 Orchestre Svmphonique de Montréal.102 St-Georges Express ( 1962) 1 i mitée.102 Simard (W.) ltée.102 Société Dicana inc.102 Société Tcrveco ltée.102 Supermarket Fashions Inc.102 Val-Martin Realties Ltd.102 Voybec Inc.102 Changement de nom Change of name Aliments Richelieu inc.(Les).98 Aménagement immobilier Satellite inc.98 Audy (G.) Plumbing Heating Ventilation Ltd.99 Bas & chaussettes Gina ltée.98 Bcaconsficld-Kirkland Combined Appeal Inc.98 Biltwell Containers Ltd.99 Blue-jean de l'Ouest inc.(Le).98 Brasserie Le Gaulois inc.(La).98 Compagnie pharmaceutique Vila ltée.98 Compagnie unifiée de Beaconsfiold-Kiikland inc.98 Compo-impro inc.98 Editions Thémis inc.98 Emballages Biltwell liée.99 Entreprises Octostop inc.Entreprises \"Sun Glow\" inc.(Les).Feco inc.99 Gina Hosiery Mills Ltd.98 Grégoire, Berthiaume, Paquette, Racicot société à responsabilité limitée.99 Immeubles Lumi inc.Industries de couture Puccini ltée (Les).99 Maisonnerie inc.99 Octostop Enterprises Inc.99 Richelieu Aliments Inc.98 Roberge (Ena) inc.99 Satellite Realties and Development Inc.98 Shalinskv, Bierbrier, Peiclman & Goldstein Inc.99 \"Sun Glow\" Enterprises Inc.99 Ventilation chauffage plomberie G.Audy ltée 99 Vita Pharmaceutical Company Ltd.98 Demandes d'abandon Applications for de charte Surrender of Charter April Fashions Inc.110 Beckenew Knitting Mills Limited.107 Bélanger & Gagné inc.106 Bijouterie Pieran inc.106 Charbonneau Hardware, Ltd.103 Comptoir du boeuf R.B.J.inc.105 Copeaux Landricnne inc.106 Darcon Inc.107 Domrémy-Québec inc.109 Equipement général (St-Félicien) ltée.107 Ferronnerie Charbonneau, ltée.103 Francs sociétaires inc.(Les).107 Furniture Pavillon Ltd.104 General Equipment (St-Félicien) Ltd.107 Hôtel Christophe inc.107 Isacella Investments Ltd.108 Labrie (Guy) Limited.108 Labrie (Guy) limitée.108 Land & Construction Company.105 Lasallc Steel Inc.108 Le Messager de Lachiuc ltée.108 Levitan (Léonard) & Associates Limited.104 McMahon Distributors Limited.104 Morola Inc.104 Multi-Investments ltée.106 Ormstown War Memorial Community Centre Inc.104 Paquet & Gagnon inc.105 Pavillon du meuble ltée.104 Peinture & décor (St.Joan) ltée.108 R.B.J.Beef Counter Inc.105 Relais routier (Charny) ltée (Le).108 Rivcrfarm Investments Limited.106 Romar (Laval) Inc.105 Sodac ltée.106 Soucy (L.-E.) inc.108 Summcrlea Industrial Park Limited.110 United Auto Parts of Vallevfield Limited____ 108 World Travel Plan (Canada) Ltd.105 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° 2 Lettres patentes Letters Patent (1™ partie) (Part I) Appareils ménagers G.D.inc.(Les).95 Atelier de débosselage St-Joseph inc.95 Bernier (P.Robert) inc.96 Blander Management Ltd.97 Boutique André Bibeau inc.96 Boutique de cadeaux Victoria inc.96 Brasseries Pont-Rouge inc.(Les).96 Candor Bullion Importers and Exporters Inc.97 Carrosserie Gonnot ltée.96 Compagnie Filtrex inc.96 Compagnie de rebuts G.D.ltée.96 Construction Lebois, Bedford (C.L.B.) ltée.96 Couvreur E.L.Savoie ltée.96 Creations S.E.C.inc.(Les).96 Distribution Vistck inc.90 Dunlop Truck Sales Ltd.98 E.J.Motors Service Inc.97 Entrepreneur général H.Tousignant ltée .96 Entreprises de dégèlement Sept-Iles inc.96 Entreprises d'électricité A.Beaudry inc.(Les).96 Entreprises F.Hébert inc.(Les).96 Entreprises L.O.R.Y.inc.(Les).96 Entreprises M.Camille inc.(Les).96 Entreprises N.A.M.inc.(Les).96 Entreprises de rebuts L.G.D.inc.(Les).96 Filtrex Co.Inc.96 Finition de plancher J.B.inc.96 G.D.Waste-Paper Co.Ltd.96 Gestimmobile ltée {Correction).248 Gestion Blander ltée.97 Gonnot Auto Body Shop Ltd.96 Hébert (F.) Enterprises Inc.96 Hôtel Le Manoir Rivière-du-Loup inc.97 Immeubles Jacdevil inc.(I-es).97 Immeubles Lemay & Pruneau ltée (Les).97 Importateurs et exportateurs de lingots Candor inc.97 Industries Carrousel inc.(Les).97 Industries Ultec inc.97 Invest Canada International Inc.97 Investissement Canada International inc.97 Investment Canada International Inc.96 J.B.Flooring Inc.96 Lachute Commission Sales (1974) Inc.98 Leclerc & Ledoux inc.97 Lépine-Cloutier ltée.97 Location Fournier inc.97 Mondimmobile ltée.97 Placements S.L.G.R.ltée (Les).97 Roumian inc.97 S.L.G.R.Investments Ltd.97 St-Joseph Body Work Shop Inc.95 Savoir (E.L.) Roofing Ltd.96 Service de moteurs E.J.inc.97 Service d'organisation fonctionnelle des groupes S.O.F.O.G.inc.(Le).97 Société Placim inc.(La).97 Société Sogsabec ltéè.97 Tafleur (David) inc.97 251 Tremblay (P.H.) & Fils inc.97 Ultec Inductries Inc.97 Vente de camions Dunlop ltée.98 Ventes à commission de Lachute (1974) inc.(Les).98 Victoria Gift Shop Inc.96 Vitrerie Vaillancourt inc.98 Lettres patentes Letters Patent (S?partie) (Part III) Association des pompiers de St-Damien de Brandon-Berthier inc.(L').103 Carrefour Pour Elle.103 Centre de prière l'Alliance inc.103 Club Argentin de Montréal.103 Club athlétique Les Cracs de Montréal.103 Club de moto-neige St-Zotique inc.103 Club optimiste Senneterre, Québec.103 Club sportif Aux Quatre Bonnes Griffes.103 Club de tennis La Saison inc.103 Communications Basse-Ville.103 Lake St-Louis Senior Citizens' Properties Inc.103 Propriétés des Aînés du lac St-Louis inc.(Les).103 Résidences Bord de l'Eau de Longueuil, inc .103 Lettres patentes Letters Patent avis de correction Notice of correction Fondation Lucie Bruneau.201 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Auto Drugstore (Québec) Ltd.94 Bay view Hospital Inc.94 Burger (Murray G.) & associés (Québec) ltée.94 Compagnie de développement agricole Rouville ltée.94 Comptoir agricole St-Roch inc.94 Corporation de l'hôpital général de Chandler.94 Courtiers en viande de Montréal inc.95 Dynamic Mining Exploration Ltd.(N.P.L.).201 Electro Mesure, inc.94 Equipement L.V.R.inc.95 Estriceram inc.95 Exploration minière dynamique ltée (L.R.P.) 201 Fondation Fournier-Ethier inc.95 Gendron Lefebvre inc.95 Industries Alarie de Malartic, limitée (Les).95 Lake St.Louis Anglers and Hunters inc.95 Listel Corporation.95 Montreal Meat Brokers inc.95 Papeterie J.Léo Gagnon inc.95 Pêcheurs et chasseurs sportifs du Lac St-Louis inc.(Les).95 Placements La Toscane ltée (Les).95 Rouville Agricultural Development Company Ltd.94 Shawnee Mines & Oils (Canada) Limited 95 Tuscany Holdings Ltd.95 252 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January il, 1975, Vol.107, No.S Siège social Head office (Article 84) (Section 84) Amos Aviation Limited.99 Bacto Chem Research Co.Ltd.100 Barbel Transport Inc.99 Binor Distributors Ltd.100 Bon-Aire Bedding Mfg.Ltd.100 Cameo Fabrics Ltd.100 Canatech Inc.100 Central Truck Lines Ltd.100 Charctte (Jacques) and Associates Ltd.100 Charette (Jacques) et Associés ltée.100 Chaussures Sorel-Tracy inc.100 Cherry River Chalets Inc.100 Compagnie de recherche « Bacto-Chem» ltée.100 Continental Home Decorating & Upholstering Co.100 Con-Vec Corporation Ltd.100 Corporation Con-Vec ltée.100 Cournoyer (Yvan) inc.100 Diamond (Arthur) Inc.100 Distributeurs Binor ltée (Les).100 Domaine des Hautes Laurentides inc.100 Dumont inc.100 Editions Flammarion ltée (Les).100 Fobec Inc.100 Fortin (Bandag) Ltd.100 Fortin (Bandag) ltée.100 G.L.R.Inc.100 General Tank Maintenance Ltd.100 Hamer Service ltée.101 Installations électriques Méga liée (Les).101 La Malbaie Investments Limited.101 Lallier automobile inc.101 Location Norman inc.101 Matéconomie ltée.101 Mega Electric Installations Ltd.101 Norman Rental Inc.101 Placements La Malbaie limitée (Les).101 Telmark Nickel Corporation (N .P.L.).101 Thetford Transport limitée.101 Vêtements forestiers V.F.ltée.101 Vincent Ltd.101 Vincent ltée.101 CURATELLE PUBLIC PUBLIQUE CURATORSHIP Avis de qualité: Notice of capacity: Bouchard, Jean-Claude .120 Giroux.Alain.120 Marchant, Thomas L.120 MINISTÈRES DEPARTMENTS Institutions Financial financières, Institutions compagnies Companies et coopératives and Cooperatives Assurances: Insurance: International Life Insurance Company (The) (Reg.61).201 Internationale, compagnie d'assurance-vie (L') (Reg.61).: \u2022 \u2022 201 Ocean Accident and Guarantee Corporation Limited (The) (Annul.).201 Terres et forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Laprairie de la Madeleine, par.110 Laprairie de la Madeleine, par.110 Stoke, canton-township.111 Stoke, canton-township.111 Régie de l'assurance- Québec Health maladie du Québec Insurance Board Professionnels désengagés et non participants.111 Withdrawn or non-participating professionals.Ill Régie de l'électricité Electricity and et du gaz and Gas Board Gaz Métropolitain, inc.(Requête-Pétition)- 203 RENSEIGNEMENTS SUR COMPANIES LES COMPAGNIES INFORMATION ACT Révocation de dissolution: Revocation of dissolution: Anita's Inc.116 Association des inspecteurs de la santé publique de la Province de Québec (L').116 Baltica Investment Corporation.117 Canadian Commodity Exchange Inc.117 Club social Galluciano.117 De Sola Club of Montreal Inc.117 Entreprises A.L.M.liée (Les).117 Entreprises Raymond & Savoie inc.(Les) 117 G.J.M.D.ltée.117 Garage Viaduc ltée.117 Hôtel Union, limitée.117 L.C.entrepreneurs généraux ltée.117 Middle-Eastern Investment Corporation.117 Ropna Inc.117 Service des loisirs St-Justin.117 Transcrane Inc.117 SOUMISSIONS TENDERS demandes de Requests for Chénier, munie.206 Coaticook, ville-town.207 La Pocatière, ville-town.204 SYNDICATS PROFESSIONNELS PROFESSIONAL SYNDICATES Syndicat des producteurs de fruits et légumes de la région de St-Hyacinthe (U.P.A.) (Const.).202 VENTES Licitation Ikonomou m Vakali.SALES Licitation .202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1975, 107' année, n° 2 253 Par Shérifs By Sheriffs Hull Hull Caisse Populaire Sacré-Coeur de Hull vs Boyer 244 Joliette Joliette Central Mortgage and Housing Corporation vs Fiorentu & al.245 Laurentide Acceptance Corporation Limited Vs Lecompte.245 Société centrale d'hypothèques et de logement vs Fiorentu & al.245 Montréal Montreal Aude! vs Laniel.246 Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe Robert vs Douais.246 Témiscamingue Témiscamingue Tagliamonte vs Raydan Mining Company Limited.247 VENTES SALES Taxes Taxes Aima, ci té-ci ty.220 Brome, comté-county.210 Compton, comté-county.219 Mont-Fort, es.222 Québec, comté-county.240 Saint-Hyacinthe, cité-city.218 St-Hyacinthe, comté-county.221 St-Jean, comté-county.217 Stanstead, comté-county.235 nouveautés Ministère des Affaires Municipales Société d'aménagement de l'Outaouais Rapport des activités pour l'année financière 1973-74 Québec, 1974.54 p., ill., 28 cm ISBN 0-7754-1951-6, reliure à spirale S 1.00 Ministère de L'Éducation Office de la langue française Terminologie technique et industrielle Lexique anglais-français de l'électronique au Québec.(électricité, radio, télévision, appareils de mesure, composants électroniques) Québec, 1974.212, (72) p., (cahier No 22) bibl., ill., 22 cm ISBN 0-7754-1943-5, broché S 3.00 Lexique de l'industrie textile Québec, 1974.VI, 240 p., (cahier no 23) 28 cm ISBN 0-7754-1944-3, broché $3.00 Terminologie de la gestion Les organigrammes Désignations et descriptions de fonctions par Leopold Larouche et Jean-Yves Pilon, sous la direction de Marcel Côté Québec, 1974.VII, 233 p., (cahier no 24) graph., 22 cm ISBN 0-7754-1945-1, broché S 3.00 Les horaires de travail Québec, 1974.16 p., bibl., 28 cm (polycopié) ISBN 0-7754-1954-0, broché $0.50 Vocabulaire général de la vente en magasin Terminologie de l'étiquetage par Marie-Eva de Villers-Sadini en collaboration, sous la direction de Jean-Claude Corbeil Québec, 1974.44 p., 28 cm (polycopié) ISBN 0-7754-1947-8, broché $ 1.00 Le mot du jour par Louis-Paul Béguin Québec, 1974.168 p., 21 X 28 cm (polycopié) ISBN 0-7754-1946-X, broché $ 1.50 Néologie en marche par Gilles Leclerc (polycopié), 28 cm No 1 Québec, mars 1973.52 p.EOQ 1774, broché $ 1.00 No 2 Québec, janvier 1974.103 p.EOQ 1948, broché $ 1.00 No 3 Québec, mars 1974.72 p.EOQ 1956, broché $ 1.00 No 4 Québec, juin 1974, 99 p.EOQ 1949, broché S 1.00 La série des 4 volumes EOQ 1960 $ 3.50 \u2022 L'ÉDITEUR OFFICIEL t DU QUÉBEC 675 EST, BOUL.ST-CYRILLE QUÉBEC SOMMAIRE Avis divers.200 Changement de nom, Loi du.117 Commission des transports du Québec.121 Compagnies, Avis concernant la Loi des 93-201 Curatelle publique.120 Ministères.110-201 Régie de l'assurance-maladie.111 Régie de l'électricité et du gaz.203 Renseignements sur les compagnies.116 Soumissions.204 Syndicats professionnels.202 Ventes: Licitation.202 Par shérifs.244 Pour taxes.210 SUMMARY Change of Name Act.117 Companies Act, Notices concerning the 93-201 Companies Information Act.116 Departments.110-201 Electricity and gas Board.203 Miscellaneous Notices.200 Professional Syndicates.202 Public Curatorship.120 Québec Health Insurance Board.Ill Québec Transport Commission.121 Sales: Licitation.202 By Sheriffs.244 For taxes.210 Tenders.204 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec Cité parlementaire, Québec G1R 4Y7 1*\tCanada Postes , Post Canada / PMttgtpKl Pd cave \tThird Troisième \tclass classe \tPermis No.107 \tQuébec REÇU LE WBUOTHÈQUÊ NATIONALE DU QUÉCCC "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.