Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 3 (no 18)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1975-05-03, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" F orr A11E8 G3/ PTIt 1 IRIDIQUES 1 ÎAL NOTICES EX.2 1 £ 3 MAI 1975 NO 18 î* GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC UAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.J mai 1975.107' année.n° 18 3523 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazelle officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mardi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le lundi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Tuesday noon; if Tuesday is a holiday, the deadline is Monday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Quebec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher 3524 QUÉBEC OFFICIAL (IAXETTE.May J, 1975.Vol.107, So.IS TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Quebec, Ciiaki.es-Hf.xri Dl'bé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (H lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dube.Quebec Official Publisher.Parliament Buildings.Québec.October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuille/, communiquer avec: Ocorges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (41S) 643-5195 Tiré.s-à-part ou abonnements: Tél.: (41 S) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec.Cite Parlementaire.Québec C1R 1V7.P.Q.For information concerning the publication of notices, please call: (ieorges LaPIKKHK Quebec Official Gazette Tel.: (41S) 643-5195 Off-prints or subscription rates: Tel.: (4IS) 643-5150 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher.Parliament Buildings.Québec G1R 1Y7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 mai 1975, 107' année, n° 18 3525 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Compagnies \u2014 Loi des\tCompanies Act Lettres patentes (Ve partie)\tLetters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation.\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating: Nom / Xamr\tIncorporation Siège social / Head Office Date AIDE TECHNIQUE TEMPORAIRE J.K.LTEE.et sa version anglaise J.K.TEMPORARY TECHNICAL HELP LTD.1371-7582\t.Montréal.18 03 75 \tHnvre S.-iint-Piprrp 07 0*2 75 1361-6735\t LES ARMURIERS DE SHERBROOKE INC.et sa version anglaise SHERBROOKE GUNSMITH IXC.1361-1074 ASSURANCES ZICAT & DIONNE INC.1361-040!\" LES ATELIERS DP LAC INC 1362-3001 ATTRACTIONS MERLIN INC 1362-2725 AUBERGE DC BON PLAISIR INC.1371-0273 AUBERGE OKFORD INC I361-7S40 AUBERT & MAROIS LTEE 1360-3725 BIJOUTERIE BERNE DUVERNAV LTEE 1361-1462 BORDELEAU & MET1VIER INC.1362-1545 12.rue Kennedy nord.Sherbrooke.07 01 75 20.rue St-Jean.suite 116, Québec.Saint-Coeur-de-Mnrie.Montréal.1010.rue Principale, Batiscan.20, rue Merry sud.Magog.AUTOMATION MECANELEC INC.1362-7773 AUTOMOBILES CHARTRAND (1075) LTEE.et sa version anglaise CHARTRAXI) ACTOMOHILE (1076) LTD.1362-0274 JEAN-PIERRE BOURGEOIS INC.1362-5710 BOUTIQUE AU COIN DES PLEURS EPANOUIES, MONTREAL LTEE and its English version BLOSSOM CORXER FLOWER SHOP.MOXTREAL LTD.1361-2684 140.rue Principale ouest.Saint-Etienne-de-Lauzon.2175, Crescent.Bureau 5, Montréal.4731, boulevard Lévesque, Laval.8, Centre d'Achat Duvernay, Duvernay-Laval 450, Godin, Vanier.Saint-Ours.1605, Maisonneuve ouest, Montréal.21 02 75 10 03 75 11 03 75 27 03 75 12 02 75 26 03 75 00 04 75 17 04 75 00 01 75 04 03 75 24 02 75 15 01 75 3526 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No, 18 Nom / Xanir Siège social / Head Office Incorporation Date LA BOUTIQUE CAPILLAIRE MICHAGO INC.1361-1942 LA BOUTIQUE DU CERF INC.1371-9539 BOUTIQUE DES DAMES INC.1361-8111 BOUTIQUE LA DIFFERENCE INC 1361-8152 BOUTIQUE MACHABEE INC .1371-6501 BOUTIQUE UNISEXE VERSEAU INC____ and its English version A0UAR1VS UNISEX BOUTIQUE IXC.1360-0994 BRAFRANC INC.1362-0414 BRIQUETERIE BOUCHER & BOUCHER INC.1361-0092 LES BRIQUETEURS ROBERT ET ROBERT INC 1362-4341 HERVE J.BUDREAU INC.1371-5826 LES CANTINES DU CHANTIER INC 1362-3400 LE COEUR LA BOHEME.1371-2807 JEAN CHOLETTE & ASSOCIES LTEE.1362-2650 LES CIMENTS MONTCALM INC .et sa version anglaise MONTCALM READY MIX IXC.1371-8754 COBLEAU INC.1371-2518 COJOM LTEE.1361-7378 LA COMPAGNIE DE LOCATION C.H.P.LTEE.1371-0058 CONFISERIE LA PETITE BOURGEOISE LTEE.1371-1866 LES CONSEILLERS EN ADMINISTRATION L.F.B.INC.1371-5453 LES CONSTRUCTIONS A.BERUBE LTEE.1361-6685 454, boulevard St-Josepli.Hull.8250.avenue Notre-Dame est, Centre d'Achat Notre-Dame.Montréal.2, boulevard Fafard, Baie-Saint-Paul.44, rue St-Germain.Rimouski.Terrebonne.95, Ste-Catherine est, Montréal.358, rue Notre-Dame est, Montréal.Route rulale numéro 1, Iberville.4020.Savard, Trois-Rivières.9159, Place de Mongolfier.Montréal.Montréal.Centre Culturel Vanier.20, rue Maples, Chateauguay-Centre.0244, des Pignerolles.Anjou.6412.chemin Lac-d'Argent.Chertsey.6501, rue St-Hubert, Montréal.7, Algonquin Drive.Lucerne.103, rue St-Pierre, Saint-Constant.Montréal.600, boulevard Dorchester ouest, 9e étage, Montréal.82, Roy, Trois-Pistoles.CONSTRUCTION A., L.& P.BERNIER INC.55, du Ruisseau, Beauport 1302-7385 CONSTRUCTION DENIS ROY INC.1371-6923 CONSTRUCTION G.A.R.INC____ et sa version anglaise G.A.R.CONSTRUCTION INC.1361-7220 Saint-Lazarre.Laval.13 01 75 02 04 75 14 02 76 14 02 75 10 03 75 04 11 74 25 02 75 21 03 75 17 03 75 05 03 75 13 03 75 20 03 75 11 03 75 27 03 75 06 02 75 13 02 75 17 01 75 31 01 75 28 02 76 07 02 75 07 04 75 12 03 75 11 02 75 GAZETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC, -J mai 197».107' année.u° IS 3527 Nom / Xame CONSTRUCTION I.ABONTE & FILS LTEE.1302-3798 CONSTRUCTION ROGER POIRIER INC.et sa version anglaise ROGER POIRIER COXSTRI'CTIOX IXC.1362-5447 CONSTRICTION VILLERO INC.1362-6031 CORBIN & TREMBLAY INC.1360-5602 LES COU VUE-PLAN CHERS Y.TREMBLAY INC.1362-7757 RAYMOND DEBLOIS INC.1362-6619 SALVATOR DE lORIS INC.1362-4507 DOMAINE CHASSE ET PECHE GAUDIAS POSTER INC.1361-6933 LES ENTREPRISES ARABEC LTEE.1360-5845 LES ENTREPRISES BEAU DOMAINE INC.1370-9878 LES ENTREPRISES CHUNG & LEE INC.et sa version anglaise CHUXG A LEE EXTERPRISES IXC.1371-4738 LES ENTREPRISES DE CUIR C.H.R.INC.1371-6352 LES ENTREPRISES DIVAC, DIVISION EQUIPEMENT INC.1371-5446 LES ENTREPRISES ELECTRIQUES R.DEPELTEAU INC.1371-8143 LES ENTREPRISES P.BERTHOLET INC.1360-6843 LES ENTREPRISES GUV RIOPEL LTEE.1361-9200 LES ENTREPRISES J.-P.BERTHELET INC.1362-0023 LES ENTREPRISES JEAN J.TRUDELLE INC.1371-2252 LES ENTREPRISES JEAN-LOUIS LESSARD INC.1371-4589 LES ENTREPRISES LISE LANGELIER LTEE.1360-8716 LES ENTREPRISES M.L.FECTEAU INC.1302-1453 LES ENTREPRISES ST-FRANÇOIS DU LAC INC.1301-2901 LES ENTREPRISES V AU BEC INC.1371-4779 Incorporation Siège social / Head Office Date SOI.nie Labonté, Saiute-Théodosie- 13 03 75 Calixa-Lavallée.Drummondville.21 03 75 13.rue Victoria* Saint-Emile.25 03 75 Chapais.03 12 74 819.3e Avenue, Val-d'Or.08 04 75 Sainte-Marguerite.02 04 75 Repentigny.18 03 75 Port-aux-Quilles, Saint-Siméon.02 04 75 390, rue Gevers, Blainville.12 02 76 4115, rue St-Denis.Bureau 1, 05 03 75 Montréal.5193, boulevard Décarie.25 02 75 Montréal.Montréal.07 03 75 15.rue Dubé, Laval.28 02 75 138, rue de la Barre.21 03 75 Boucherville.Laval.09 12 74 550, rue St-Zotique est, Montréal.19 02 75 2199, rue Marie-Anne, Montréal.25 03 75 507, rue Frechette, Saint-Hilaire.03 02 75 22.rue Greenfield, Dollard-des- 24 02 75 Ormeaux.1800, rue Ste-Catherine ouest, 17 12 74 Montréal.191, 20e Rue, Saint-Georges-Est.28 02 75 Saint-François-du-Lac.17 01 75 487, boulevard Duhamel, Pincourt____ 25 02 75 352S QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE.Ma// J.197».Val.107.Xo.18 Nom / Xantr LES ENTREPRISES 7.BENOIT INC.1302-5330 ENTREVAL INC.1301-9002 EQUIPEMENTS DE BUREAU ST-EL'OENE INC.1301-0791 GARAGE C.M.S.R.INC.13G2-3749 RAYMOND GOIliLAY INC.1301-8798 JACQUES GUILLEMETTE INC.1302-2238 LES HABITATIONS CHRISTIAN INC.1301-9440 LES HABITATIONS V.I.I'.INC.et sa version anglaise V.I.P, HOMES IXC.1371-4480 HEBEKT, BRODEUR & ASSOCIES LTEE.1371-4514 BRUNO HELIE INC.1362-3301 LES IMMEUBLES KENKO LTEE.et sa version anglaise KEXKO REALTIES LTD.1362-5181 LES IMPORTATIONS EPOCA LIMITEE.1371-7434 LES IMPORTATIONS G.& E.INC.et sa version anglaise G.& E.IM PORTS IXC.1362-2840 LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUTAIRES DE L'AVENUE WICKSTEED LTEE et sa version anglaise WICKSTEED AVENUE COMMUX1TY INVESTMENTS LTD.1371-6881 ISOLATION D.G.LTEE.et sa version anglaise D.G.INSULATION LTD.1371-7731 JACMEDIC LTEE.1362-8342 LES JARDINS BERNIERES LTEE.1362-4374 LES JARDINS KALIVALA LTEE.et sa version anglaise KALIVALA GARDENS LTD.1362-5439 JOCA INC.1371-3839 JOUETS CADET ROUSSELLE (TERREBONNE) INC.et sa version anglaise CADET ROUSSELLE TOYS (TERREBONNE) INC.1371-8101 Incorporation Siège social / Head Office Date 1800, boulevard Miljours.Val-d'Or .21 03 75 Saint-Étienne-de-Lauzon.19 02 75 125.rue St-Laurent, Salaberry-de- 07 02 75 Valleyfield.3815, Maurice, La Plaine.13 03 75 1320, boulevard Mercure, Drummond- 18 02 75 ville-Sud.1700.Père Daniel, Trois-Rivières 05 03 75 439, boulevard des Cimes, Neufchâtel.21 02 75 734, boulevard Châleauneuf, 24 02 75 Boisbriand.500, Kleber, Duvernay, Laval.24 02 75 Bécancour.12 03 75 Montréal.19 03 75 357, avenue Stanstead, Mont-Royal.17 03 75 Montréal.07 03 75 625, avenue Président Kennedv, 12 03 75 Bureau 903, Montréal.1615, rue Du Domaine, Montréal.19 03 75 Québec.11 04 75 204, rue Plante, Bernières.17 03 75 635, chemin de la Rivière, Piedmont.21 03 76 Laval.19 02 76 1185, boulevard Moody, Terrebonne.20 03 75 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S mai 1975.107' année.»' IS 3529 Nom / XûMe RAYMOND LAURENDEAU INC.1302-0338 BENOIT LEDUC INC.13GI-4805 LETHER INC.1302-0323 LIBRAIRIE MICHELE FAURE INC.1371-9210 LIBRAIRIE VEILLECX INC.et sa version anglaise VEILLECX STATIONERY INC.1361-0008 LITHO DELTA INC.1371-3250 LUBRIFIANTS C.RAND PRIX INC.1300-7643 MANOIR DE LA VALLEE EATON INC.and its English version BATON VALLEY MANOR INC.1360-9722 MATERIAUX DE CONSTRUCTION SOLNEA LTEE 1371-6816 MERCERIE POUR HOMMES P.B.A.INC.1361-5471 MARCEL MERCIER INC .1371-3235 MEUBLES J.DUMoNT INC.1362-1735 LES MEUBLES DE KIMOUSKI INC.1362-0117 MOTEL CHATEAU STE-JULIE INC.1362-5892 LES PAVAGES ETNA INC.et sa version anglaise ETNA PAVING INC.1371-9158 GAETAN PAYANT INC.1362-4457 PAYSAGES POINTE-AUX-TREMBLES INC.1362-6585 LES PEINTURES M.J.LTEE.et sa version anglaise M.J.PAINTS LTD.1361-6800 PHOTO JULES INC.1371-8770 PHYSIATECH AHUNTSIC INC.1361-6628 LES PLACEMENTS COLLITZ LTEE et sa version anglaise COLLITZ INVESTMENT LTD.1371-3458 Siège social / Head Office Incorporation Date 3411.boulevard Ste-Béatrix, 26 Saint-Ambroise-de-Kildare.Saint-Étienne.28 Baie-Trinité.24 1185, rue Moody.Terrebonne.01 Lasalle.04 Montréal.13 356, 15e Avenue, Iberville 11 Sawyerville.20 615.Dorchester ouest.13 Bureau 1010, Montréal.Montréal.03 Saint-Etienne.13 Cabano.03 470.rue St-Germain est, 21 Rimouski.Sainte-Julie.27 4689, Arainis, Montréal.01 Valleyfield.n 13,853, rue Victoria, Pointe- 01 aux-Trenibles.Soint-Ambroi.se.10 319, rue Brunelle, Beloeil.27 3509, boulevard de la Concorde, 07 app.204, Laval.400.rue Craig ouest, Montréal.17 03 75 01 75 02 75 04 75 02 75 02 75 12 74 12 74 03 75 02 75 02 75 03 75 02 75 113 75 04 75 03 75 04 75 02 76 03 75 02 75 02 75 3.330 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.IS Nom / Name LES PLACEMENTS DE LAUNIERE INC.1371-6188 PLACEMENTS GAETAN LACOMBE INC.1371-6824 LES PLACEMENTS QUEVER INC.1371-1577 LES PLACEMENTS ST-PATRICK LTEE.1361-7717 LES PLACEMENTS STANISLAS INC.1361-3534 LES PLANCHERS ERIC INC.1361-7725 POMPE ET FILTRATION NORD-EST INC.1361-6347 PORTES ET CHASSIS CLEMENT FORTIN INC.1371-8762 PUBLICITE PARIS INC.1362-6635 QUEBEXPLO INC.1362-2808 REFRIGERATION G.L.INC.et sa version anglaise G.L.REFRIGERATION INC.1371-1122 REFRIGERATION & VENTILATION MIKE INC.1362-2394 REMBOURRAGE CLAUDE SEVIGNY INC.1371-3557 LES REMBOURREURS R.H.INC.1370-4598 RESTAURANT KAMLING INC.et sa version anglaise KAMLING RESTAURANT INC.1371-3185 RESTAURANT PUCCINI (1975) INC.1362-4150 ROBES DIANE INC.et sa version anglaise DIANA DRESS INC.1370-8367 FRANCOIS ROY INC.1362-0208 LEO-PAUL ROY' INC.1362-2378 SALON FUNERAIRE McCONNERY INC.et sa version anglaise McCONNERVS FUNERAL HOME INC.1362-1024 SANINET INC.1361-7287 SERRURIERS COTE, FLEURY, CANTIN INC.1361-2627 Incorporation Siège social / Head Office Date 117, rue St-Charles nord, .loliette.06 03 75 Montreal.H 03 75 Phillipsburg.29 01 75 414, rue Queen, Rawdon.12 02 75 34, Argyle.Saint-Lambert.21 01 75 Saint-Augustin.12 02 75 829, 2e Avenue, Limoilou.06 04 75 190, de l'Eglise, Napierville.27 03 75 39, rue St-Antoine, Sainte-Marie- 02 04 75 de-Beauce.3465, Westmore, Montréal.10 03 75 78, rue DeMontigny, Sainte-Agathe- 27 01 75 des-Monts.240, boulevard Alexandre-Taché, 06 03 75 app.604, Hull.120-25e Avenue, Grande-Côte 20 03 75 Saint-Eustache.Montréal.21 11 74 6338, rue Sherbrooke est.13 02 75 Montréal.816, rue Parfondeval.Hauterive.13 03 76 3396.rue Jean-Talon est, Montréal.27 12 74 Aumond.24 02 75 Saint-François-de-Beauce.06 03 76 204, rue Cartier, Maniwaki.27 02 75 248, rue Frontenac, Rimouski.11 02 75 315 B, de la Canardière, Québec.15 01 75 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 mai 1975.107' année.n° 1S 3531 Nom / Name SERVICE DE DESSIN TECHNIQUE MILLE ILES INC.and its English version MILLE ILES DRAFTING SERVICE INC.1370-8748 LES SERVICES DE LAVAGE J.R.R.DRUMMOND INC.1362-0745 SERVICE DE MESSAGER SPECIAL LIMITEE.et sa version anglaise SPECIAL MESSENGER SERVICE LIMITED 1361-9358 LES SERVICES SANITAIRES D'ALMA INC.1362-4101 LA SOCIETE GRECO INC.1361-7188 SOCIETES DES HOTELS MERIDIEN (CANADA) LTEE.1362-1719 SOGESCAL INC.13-712583 SPORT-NAT INC.1362-7690 SUPERMARCHE ARCAND INC.1361-6982 TAVERNE OUIMET INCORPOREE.1361-7089 TAXI M IRON INC.1371-7186 TELDIS NC.1371-7996 TERRASSE DUVERNAY (1975) LTEE.1362-7328 LES TISSUS MIGOR INC.et sa version anglaise MIGOR FABRICS INC.1371-3862 TRANSFRUIT INC.1362-3806 TRANSPORT H.SENECAL INC.1362-2402 TRANSPORT MISTACAMIE INC.1362-0315 TRASAC INC.1362-6346 VAILLANCOURT & MERCIER INC.1362-1214 VEILLEUX F:T NADEAU INC.1362-5827 VITRERIE D.C.PLYPANE INC.et sa version anglaise D.C.GLASS PLYPANE INC.1371-6444 Incorporation Siège social / Head Office Date 305, Grande-Côte, Rosemère.03 01 75 440, rue St-Georges, Drummondville.26 02 75 Montréal.20 02 75 1271, avenue Blanchard-nord, Aima.14 03 75 Sherbrooke.31 09 74 Montréal.03 03 75 Repentigny.14 03 75 820, boulevard Taschereau, 07 04 76 Greenfield Park.547, rue St-Louis, La Tuque.11 02 75 3873, rue Ontario est, Montréal.10 02 75 2685, rue de Blois, Duvernay, Laval.13 03 75 Montréal.20 03 75 2945, De Normandville, Trois-Rivières 01 04 76 100.rue de Gaspé, bureau 1408.26 02 75 Ile-des-Soeurs, Verdun 1775, McNamara, Laval.13 03 75 1939, rue Alexandre-de-Sève, 06 03 75 Montréal.792, rue Laflamme, Chibougamau.24 02 76 1110, Sherbrooke ouest, Montréal.26 03 75 16, rue Comeau, Maniwaki.27 02 75 Sainte-Marie.24 03 75 9900, boulevard Ray Lawson, Anjou.06 03 75 60688-O Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardinb.60688-O Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. 3532 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May S, 1975, Vol.107.No.18 Lettres patentes (3e partie)\tLetters Patent (Part III) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating: Nom / Name\tIncorporation Siège social / Head Office Date ASSOCIATION DES DIRECTEURS DES BUREAUX LOCAUX DE L'AIDE SOCIALE DU QUEBEC 1370-6692 ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES DU SAGUENAY LAC ST-JEAN 1360-6322 L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CHAUVEAU INC.1361-5430 ATELIERS DE LOISIRS CULTURELS DE SENNETERRE., .1362-1446 CHAMPIONNAT MONDIAL JUNIOR DU PENTATHLON MODERNE INC.et sa version anglaise MODERN PENTATHLON JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP INC.1361-5034 CLUB DE CHASSE ET PECHE CADIEUX DU GRAND CALUMET INC.1360-2180 CLUB LIONS CHICOUTIMI INC.1361-6388 LE CLUB DE MOTONEIGES LES MONTAGNARDS DE FORILLON INC.1362-6403 LE CLUB OPTIMISTE DE MANIWAKI, QUEBEC 1361-0560 LE CLUB DE PATINAGE AYLMER-LUCERNE et sa version anglaise AYLMER-LUCERNE SKATING CLUB 1361-7238 CLUB SOCIAL BARANELLO.1361-0423 COMITE CULTUREL DE LA GUADELOUPE INC.1362-1461 LE COMITE PROVINCIAL DES MALADES INC.1369-6612 L'EXPO-SCIENCE DE L'ESTRIE INC.1362-1354 LOISIRS SECTEUR-OUEST NEUFCHATEL.1360-5282 REGROUPEMENT DES AVEUGLES DE LA REGION DE QUEBEC INC.1358-5617 SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT-CARTIER.1358-4867 1001, 4e Avenue, Limoilou.14 03 75 310, rue Hôtel-de-V'ille, Chicoutimi.05 12 74 19, Louis-Hébert.Loretteville.21 02 75 Senneterre.28 02 75 25.Croisant-Notre-Dame.29 01 75 Duvernay, Laval.Grand-Calumet.12 11 74 Chicoutimi.06 02 75 Gaspé.10 12 73 Maniwaki.07 02 75 Aylmer.il 02 75 7360, rue Louis-Hémon, Montréal.30 12 74 La Guadeloupe.28 02 75 16 09 74 Sherbrooke.27 02 76 129, Carré Provence, Neufchàtel.07 04 75 19 02 76 1, Carré Westmount, Bureau 460.Westmount.1374, avenue de l'Eglise.Val-Bélair.Port-Cartier.13 08 74 OO688-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.OO688-0 Pierre Desjardins, Director 0/the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mai 1975.107' année, »\u2022 18 3533 Avis de correction (Lettres patentes) Notice of correction (Letters patent) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a autorisé la correction de lettres patentes suivantes: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has authorized the correction of the letters patent issued to the following companies or corporations: Nom / Name Siège social Incorporation Head office Date Modifications Corrections AMENAGEMENTS HEMISPHERE INC.et sa version anglaise HEMISPHERE DEVELOPMENT INC.1368-9781 CLUB CANIN DU QUEBEC INC.et sa version anglaise QUEBEC DOG CLUB INC.1242-7225 RADIO AMATEUR SAGUENAY-LAC- SAINT-JEAN 734463 1, Carré Westmount, Westmount.225, Paradis.Duberger.283, Notre-Dame, Jonquière.01 08 74 Remplaçant le siège social :/ Replacing the head office: 1.Carré Westmount, Montréal, par / by 1, Carré Westmount, Westmount.22 12 69 Substituant dans les lettres patentes les mots « 1ère partie » par « 3e partie ».Substituting in the letters patent the words \"Part III\" for \"Part 1\".28 01 74 Substituant dans les lettres patentes les mots a 3e partie » par « l'article 217 n.Substituting in the letters patent the words \"section 217\" for \"Part III\".Le directeur du service des compagnies, 60688-0 Pierre Desjardins.\tPierre Desjardinb, 6068S-o Director of the Companies Service.Lettres patentes supplémentaires\tSupplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de ta Loi des compagnies U a accordé des lettres patentes supplémentaires à:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Change* B.L.P.CONSTRUCTION INC.11 08 65 1239-3906 CENTRE DE PROTHESES AUDITIVES ATLAS 17 12 71 INC.et sa version anglaise ATLAS HEARING AIDS CENTER INC.1234-7688 LE CLUB DE BASEBALL LES CARNAVALS DE 29 01 71 QUEBEC INC.1236-3925 CREDIT STANSTEAD INC.et sa version anglaise STANSTEAD CREDIT INC.1161-6067 L'EQUIPE DE CROSSE LES CARIBOUS DE QUEBEC INC.et sa version anglaise QUEBEC CARIBOUS LACROSSE TEAM INC.1360-5357 20 03 75 Modifiant le capital./ Altering the capital.26 03 76 Etendant les objets./ Extending the objects.03 04 75 1.Changeant le nombre des administrateurs./ Changing the number of directors.2.Modifiant quelques dispositions des lettres patentes./ Amending some provisions of the letters patent.02 04 63 09 12 74 Modifiant le capital./ Altering the capital.29 11 74 21 03 76 Ancien nom / Former name: L'EQUIPE DE CROSSE LES CARIBOUS DE QUEBEC INC.et sa version anglaise QUEBEC CARIBOOS LACROSSE TEAM INC. 3534 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.18 Incorporation L.P.S./ S.L.P.Modifications Nom / Name Date Date Change) FERRATE INC.1171-7691 31 08 65 09 12 74 FIRST NATIONAL FUNDING CORPORATION 10 07 69 3135-69 LES INDUSTRIES H.W.S.INC.24 10 65 et sa version anglaise H.W.S.INDUSTRIES INC.1146-9343 LES INVESTISSEMENTS PAUL E.POULIN 24 12 65 INC.5694-1965 LEDPO INC.725843 25 10 72 LOCATION ROMA INC.12 05 71 et sa version anglaise ROMA RENTAL INC.2166-1971 METIERS D'ART LA CANADIENNE INC.11 05 66 1984-1966 PARC SAFARI AFRICAIN (QUEBEC) INC.05 08 71 et sa version anglaise AFRICAN SAFARI PARK INC.1223-8986 PASARD INC.15 07 63 3106-63 ROUSSEAU 4 FRERE INC.14 02 50 1155-0159 SABLIERE ST-PIERRE LTEE.12 11 64 5080-1964 LE SALON DU SON P.C.INC.11 03 64 1157-1866 LA SOCIETE DE GESTION IGESCO INC.738278 SQUARE DECARIE INC.et sa version anglaise DECARIE SQUARE INC.1054-1965 VOLUMEX LTEE 716772 07 12 71 1.Modifiant le capital./ Altering the capital.2.Étendant les objets./ Extending the objects.3.Modifiant les dispositions des lettres patentes./ Amending the provisions of the letters patent.19 03 75 Modifiant les dispositions des lettres patentes./ Amending the provisions of the letters patent.28 02 75 Ancien nom: / Former name: HUNTINGDON WOOD SPECIALTIES LIMITED.24 03 75 Mofifiant le capital./ Altering the capital.06 01 75 Modifiant quelques dispositions des lettres patentes./ .4 mending some provisions of the letters patent.27 03 75 Modifiant le capital./ Altering the capital.go 12 74 Ancien nom: / Formel- name: ROBERT LARIN INC.17 03 75 Étendant les objets./ Extending the objects.24 03 75 Étendant les objets./ Extending the objects.10 02 75 1.Modifiant le capital.Altering the capital.2.Modifiant les privilèges et restrictions-Modifying the privileges and restrictions.11 02 75 Étendant les objets./ Extending the objects.07 02 75 1.Ancien nom / Former name: GIPFARD DRIVE YOURSELF INC.2.Étendant les objets./ Extending the objects.26 09 73 30 12 25 03 65 12 03 7 4 Ancien nom: / Former name: COGENEX INC.'5 Ancien nom: / Former name: CARRE DECARIE INC.et sa version anglaise DECARIE SQUARE INC.19 03 75 Modifiant certaines dispositions des lettres patentes./ .4mending some provisions of the letters patent.60688-o let directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.Ml iXK-\u201e Pierre Dtsj.vnniNs Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1975, 107' année, n° 18 3535 Domicile légal (Article 30) Legal domicile (Section 30) Avis est donna nue les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont établi leur bureau principal ou l'ont changé whose naines follow have established their principal office or tel qu'indiqué ci-après.have changed it as indicated hereinafter.Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address ABERTON CO.(CONVERTING) LTD.12 II 1111-2711 AGENCE DE SECURITE JEAN-MARC INC____ 04 04 1368-5912 G.F.AIKINS COMPANY LIMITED .29 05 1111-2190 LES AMENAGEMENTS IMMOBILIERS AREM 06 08 INC.et sa version anglaise AREM PROPERTY MANAGEMENT INC.1369-2355 LES AMENAGEMENTS WINDERMERE INC.10 06 et sa version anglaise WINDERMERE DEVELOPMENTS INC.1368-5912 APPROVED APPAREL TRIMMINGS INC.30 07 1233-2631 ARNOTT ROGERS BATTEN LTD.29 12 1111-8965 ARONOFF BROS.LIMITED.28 11 1108-9018 ASSURANCE-VIE JEAN-GUY\" LEGAULT LTEE 13 01 1361-2056 AUBERGE HOLLANDAISE MORIN HEIGHTS 18 09 INC.1359-1961 LES AUBERGES RICHELIEU INTERNA- 26 03 TIONAL LTEE et sa version anglaise RICHELIEU INNS INTERNATIONAL LTD.1367-4478 H.L.AXLER INC.06 03 1110-9402 BARBALIC STEEL SALES CORP.25 11 1109-4257 BARON FABRICS CO.LTD.15 03 1110-1821 S.BLUM INC.17 05 1110-6648 BOND TEXTILES LTD.07 04 1110-2415 BRIAN YL LTD.21 08 1110-5039 62 1840, rue Parthenais, 5320, rue MacDonald Montréal.(Suite 907), Côte-Saint- Luc.73 2502, rue Cartier, Sainte- 1750, rue Josée, Sainte- Julienne.Julienne.50 Montréal.9320, rue St-Laurent, Montréal.74 Montréal.800, Place Victoria, bureau 2401, Montréal.74 Montréal.400, boulevard Métropo- litain, Autoroute 2 et 20, Montréal.65 Montréal.4530, Côte-des-Neiges, bureau 607.Montréal.55 Montréal.460, rue Ste-Catherine ouest, Montréal.31 Montréal.5050, rue Iberville, Montréal.75 Montréal.2190, Capitaine-Bernier, Montréal.74 Morin Heights.Route rurale numéro 1.Morin Heights, 74 3585, rue Berri, Montréal.505, rue Sherbrooke est, Montréal.54 Montréal.1470, rue Peel, Montréal.58 Montréal.1437, rue Crescent, Montréal.67 1149-B, avenue Mont- 5335, rue Casgrain, Royal est, Montréal.Montréal.65 Montréal.1255, rue Université, suite 1418, Montréal.67 Montréal.111, rue Chabanel ouest, Montréal.69 Drummondville.640, rue Hériot, Drummondville. 3536 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.18 Domicile légal Incorporation Legal domicile Nom de la compagnie- Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address BROWN DERBY DELICATESSEN & 14 08 64 Montréal.4863, rue Van-Home, RESTAURANT INC.Montréal.1102-6382 BUREAU D'ACHATS ALLISTER LTEE.11 07 49 Montréal.40, Eiffel, Place Bona- et sa version anglaise venture, Montréal.ALLISTER BUYING OFFICE LTD.1110-6390 TERRY BURNERS INC.23 08 61 Montréal.5015, rue Buchan, 1109-3093 Montréal.CANADA DACTYLOGRAPHE INC.25 01 54 Montréal.7035, avenue du Parc, et sa version anglaise Montréal.CANADA TYPEWRITER 1104-6695 CANADA-EUROPE HARDWARE IMPORT LTD.30 11 66 Montréal.5679, Fullum, Montréal.1105-1269 CANADIAN OUTFITTING CO.LTD.27 02 23 Montréal.4416, boulevard St- 1102-8842 Laurent.Montréal.CARTIER TRADING CORP.10 03 64 1435, rue St-Alexandre, 6600, rue St-Urbain.1111-3842 bureau 1083, Montréal.bureau 504, Montréal.CENTRE D'ART COMMERCIAL INC.16 09 53 Montréal.491, rue Vitré, Montréal.et sa version anglaise COMMERCIAL ART CENTER INC.1112-6729 CLUB LES VIEUX DUCKS INC.16 03 60 Greenfield Park.255, rue Hubert, C.C.P.31-60 Greenfield Park.COMMODITY INVESTMENT CORP.31 01 59 Montréal.4141, rue Sherbrooke ouest, 14793-58 Montréal.LA COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES 15 08 45 Montréal.2485, Saint-Patrick, D'OUTREMER LIMITEE Montréal, et sa version anglaise OVERSEAS CHEMICALS COMPANY LIMITED 1110-8115 LA CORPORATION DES FACTEURS CON- 19 09 73 Montréal.800, Carré Victoria, TINENTAL 3400, Tour de la Bourse, et sa version anglaise Montréal.CONTINENTAL FACTORS CORPORATION 738190 CRANKSHAFT GRINDER INC.19 11 64 820, rue Notre-Dame 220, rue Young Montréal 1195-6761 ouest, Montréal.\" DANEL LINGERIE LIMITED.12 12 68 Montréal.1588, rue Ste-Catherine 1102-9253 est, Montréal.DECORATION INTERIEURE DEUX MILLE 14 11 74 Baie-Comeau.300.boulevard LaSalle UN INC.Baie-Comeau.1360-2669 DE MONTIGNY AUTOMOTIVE CORPORA- 05 01 67 Montréal.1160, boulevard de Maison 1,09™ , neuve, Montréal.P.DIAL INC.11 03 58 Montréal.3829.rue Ontario est 1103-4014 Montréal.ECOLE DE CONDUITE DE L'ESTRIE INC- 22 01 76 Sherbrooke.261, rue Lavallée 1361-3732 Sherbrooke.' GAZETTE OFF ICI El.LE DU QUÉBEC.3 mai 1075.107' année.n° 18 3537 Domicile légal Incorporation Legal domicile Nom de la compagnie - Xame of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address ECONOMIC TRADING LTD.1111-0202 ERN EST-ALLEN CO.1109-3622 EXACT WEIGHT SCALE COMPANY (QUEBED) LTD.1105-6439 LA FEDERATION AUTO-QUEBEC INC.et sa version anglaise AUTO-QUEBEC FEDERATION INC.1368-1002 FORGET & POIRIER, INC.1109-5205 A.FORTIN TELEVISION INC.1104-9061 FREDERICK'S MEN'S WEAR LTD.1104-0318 GAUTHIER AUTOMOBILE LIMITEE.et sa version anglaise (GAUTHIER AUTOMOBILE LIMITED) 1105-6033 25 06 57 Montréal.19 07 45 Montréal.24 12 52 Montréal 04 12 73 Montréal 10 01 58 Montréal.28 04 59 Montréal 28 09 64 Montréal.GLAZERSINC.1109-0735 THE GOMAT CORP.1109-7110 18 03 49 1295, rue Bellechasse, Montréal.02 07 47 906.rue St-Denis.Montréal.GRAY ELECTRIC COMPANY.1109-6625 13 06 60 Montréal.10 06 60 Montréal.GREKnCLARE HOLDINGS LTD.4021-67 IMPREGILO & SPINO LTEE.et sa version anglaise IMPREGILO & SPINO LTD.734115 INDUSTRIAL PROJECTS LIMITED 1110-9725 LES INSTITUTIONS PRIVEES D'ENSEIGNEMENT DE LA CONGREGATION DES SOEURS DES SAINTS NOMS DE JESUS ET MARIE 1356-7441 INTERNATIONAL PAPER SALES COMPANY INC.1110-5004 22 09 67 1.Place Ville-Marie, suite 3635, Montréal.10 09 73 Montréal.07 08 63 Montréal 13 05 74 Outremont 29 07 38 Montréal ITEX LTD.1111-0103 PIERRETTE LAFRANCE INC.1358-1335 C.LA VIGNE ET FILS INC.1109-7532 LETOVSKY BROS.LTD.1100-8257 02 12 66 Montréal.22 01 74 Chute-aux-Outardes.28 10 55 Montréal.61 2324, rue Orléans, Montréal.1315, boulevard de Maison-neuve ouest, bureau 615.Montréal.976, rue Laçasse.3e étage, Montréal.1504, rue Notre-Dame ouest.Montréal.1415, Jarry est, Montréal.400, boulevard Maison-neuve ouest, Montréal.47.rue Fleury ouest, Montréal.1407, rue Crescent, Montréal.1305.rue Bellechasse, Montréal.481, rue De Vitré ouest.Montréal.100, rue Louvain ouest, Montréal.446.rue Ste-Hélène, Montréal.800, Flan Victoria, suite 2104.Montréal.275.rue St-Jacques, Montréal.3300, boulevard Cavendish, bureau 145, Montréal.1420, boulevard Mont-Royal.Outremont.1155, rue Metcalfe, Edifice Sun Life, Montréal.Q 10.Ontario ouest.Montréal.262.rue Validée, Chute-aux-Outardes.2461, rue Des Carrières, Montréal.5105-A, rue Fisher, Montréal. 353S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3.7975, Vol.107.No.18 Nom de la compagnie Name of the^company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address S.LEVINE & SONS LIMITED.02 1103-0756 LA LINGERIE HUGUETTE FROMENT INC.16 734551 D.W.LUNN & ASSOCIES LTEE.15 et sa version anglaise D.W.LCNN * ASSOCIATES LTD.1354-9209 MADELLE INC.02 1104-1670 LES MAGASINS ACCENT LTEE.16 et sa version anglaise ACCENT STORES LTD.1108-8283 MAHARAJA TICKING & TEXTILES INC.11 110-2068 MANUTENTION BEAUCHESNE INC.08 6120-68 MARCHE CHARBONNEAU LTEE.25 1101-2549 MERCURY OFFICE SUPPLIES INC.25 1104-8212 METROPOLITAN LADIES WEAR LTD.22 1103-1473 MID-TOWN ELECTRIC INC.19 1104-8352 MILLET COMPANY LTD.01 1109-3812 MILLFOAM INC.27 1109-6914 MINERALS & CHEMICALS LTD.17 1110-7976 MISSION QUEBEC '76' INC.10 733922 I.NANTEL INCORPOREE.29 1105-359 NORTHSPORT LTD.16 1111-3776 PAINT SPECIALTY LIMITED.19 1105-3667 PREMIUM & GIFT DISTRIBUTORS LTD.03 1111-6357 PRESCOTT & COMPANY LTD.28 1110-8271 QUINT HARDWARE LTD.21 1105-3840 REGAL TRADING COMPANY LTD.30 1110-8354 04 63 Montréal.10 73 37, Place Bourget sud, Joliette.03 74 1010, rue Ste-Catherine ouest, bureau 1212, Montréal.4416, boulevard St-Laurent, Montréal.65.Place Bourget sud, Joliette.2121, rue Tupper, bureau 1608, Montréal 06 61 Montréal.3636.rue Ontario est, Montréal.01 63 Montréal.1255, Carré Philips, bureau 210, Montréal.07 66 Montreal.8350, rue Jeanne-Mance.Montréal.01 69 40.Montée Ste-Julie.831, Montée Ste-Julie, Sainte-Julie.Sainte-Julie.03 64 Montréal.3920, rue Rachel est.Montréal.03 63 Montréal.234.rue St-Paul, Montréal.02 2\" Montréal.1401, rue Legendre ouest, bureau 102, Montréal.02 54 Montréal.1240, rue Mansfield, Montréal.03 63 Montréal.8185.rue Atherton, Montréal.03 61 Montréal.8350, rue Jeanne-Mance, Montréal.11 43 Montréal.1117, rue Ste-Catherine ouest, Montréal.09 73 Montréal.1415, rue Jarry est, Montréal.11 49 Montréal.1717, boulevard Maison neuve est, Montréal.04 64 140, boulevard 5000, rue Buchan, Crémazie, Montréal.Montréal.09 59 Montréal.2165, rue Frontenac, Montréal.03 67 Montréal.4980, rue Fulton, Montréal.02 63 Montréal.5625, rue Paré, Montréal.06 57 Montréal.4690, rue Cumberland, Montréal 11 56 296, rue St-Paul ouest, Montréal.5255, rue Ferrier, Montréal. GAZETTE GEE ICI ELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1975, 107' année, n° 18 3539 Nom de la compagnie .Name of Ihe company Incorporation D»te Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse A'cuj address REGINA TOBACCO & CONFECTIONERY CO.24 08 53 Montréal.6555, rue Jeanne-Mance, LTD.Montréal.RELIABLE SMALL-WARES CO.LTD.16 11 53 261, rue Ste-Catherine 46U, rue McGill.1109-2533 ouest, Montréal.Montréal.NOEL RHEAULT INC.07 07 67 Montréal.790.rue Créraaiie est.1106-3286 Montréal.ROSE-TEX MILLS LIMITED.29 08 57 Montréal.390.rue Craig ouest.1110-5012 Montréal.ROY & FILS LTEE.22 12 47 Montréal.3399.boulevard Métro- et sa version anglaise politain est, Montréal.ROY dont le siège social est situé à Notre-Dame-de-la-Doré dans le district électoral de Roberval.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 607l6-o Albert Jessop.Town of Saint-Pascal Pursuant to section 44 of the Real Estate Assessment Act, I hereby order that the limits of the territory of the Québec District of the Québec Real Estate Revision Board be modified to include therein the territory of the Town of Saint-Pascal.The present order shall come into force on the date of its publication in the Québec Official Gazette.Québec, April 15, 1975.Victor C.Goldbloom, 60744 Minister of Municipal Affairs.Cooperative Associations ASSOCIATION COOPERATIVE D'HABITATION D'ALBANEL (Cooperative Associations Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to the Cooperative Associations Act, he has approved the formation of an association under the name of \"ASSOCIATION COOPERATIVE D'HABITATION D'ALBANEL\".whose head office is located in Albanel, in the Electoral District of Roberval.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60714 Companies and Cooperatives.CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DE CHIBOUGAMAU (Cooperative Associations Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to the Cooperative Associations Act, he has approved the formation of an association under the name of \"CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DE CHIBOUGAMAU\".whose head office is located in Chibougamau in the Electoral District of Abitibi-East.Albert Jr.ssor, Depulg Minister of Financial Institutions, 60715 Companies and Cooperatives.LA COOPERATIVE FUNERAIRE DE LA DORE (Cooperative Associations Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to the Cooperative Associations Act, he has approved the formation of an association under the name of \"LA COOPERATIVE FUNERAIRE DE LA DORE\", whose head office is located in Notre-Dame-de-la-Doré, in the Electoral District of Roberval.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60716 Companies and Cooperatives. 3584 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.18 Curatelle publique Succession Georges Basilio Succession de Basilio, Georges, en son vivant de Montréal, décédé le 21 mai 1974.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boulevard St-Laurent, Montréal (Que.) H2N 1N6 60694-o Succession J.Patrice Boudreault Succession de Boudreault, J.Patrice, en son vivant de Montréal, décédé le 25 juin 1972.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boulevard St-Laurent, Montréal (Que.) H2N 1N6 60695-o Succession William Churchill Succession de Churchill, William, en son vivant de Montréal, décédé le 4 août 1974.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boulevard St-Laurent, Montréal (Que.) H2N 1X6 60696-o Succession Noël Collin Succession de Collin, Noël, en son vivant de Montréal, décédé le 20 septembre 1974.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boulevard St-Laurent, Montréal (Que.) H2N 1N6 60697-o Public Curatorship Estate of Georges Basilio Estate of the late Basilio, Georges, in his lifetime of Montreal, deceased May 21st, 1974.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2N 1N6 60694-o Estate of J.Patrice Boudreault Estate of the late Boudreault, J.Patrice, in his lifetime of Montreal, deceased June 25th, 1972.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2N 1N6 60695-o Estate of William Churchill Estate of the late Churchill, William, in his lifetime of Montreal, deceased August 4th, 1974.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2N 1N6 60696-o Estate of Noël Collin Estate of the late Collin, Noël, in his lifetime of Montreal, deceased September 20th, 1974.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2N 1N6 60697-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mai 1975, 107' année, n° 18 3585 Succession Frederick Coleman Succession de Coleman, Frederick, en son vivant de Montréal, décédé le 8 novembre 1974.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boulevard St-Laurent, Montréal (Que.) H2N 1N6 60698-o Estate of Frederick Coleman Estate of the late Coleman, Frederick, in his lifetime of Montreal, deceased November 8th,1974.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Quebec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2N 1N6 60698-o Succession Joseph M.Cunningham Succession de Cunninghan, Joseph M., en son vivant de Ste-Agathe-des-Monts, décédé le 6 septembre 1972.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succès, ion et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boulevard St-Laurent, Montréal (Que.) H2N 1N6 60699-o Estate of Joseph M.Cunningham Estate of the late Cunninghan, Joseph M., in his lifetime of Ste-Agathe-des-Monts, deceased September 6th 1972.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2N 1N6 60699-o Succession Henry Ferguson Succession de Ferguson, Henry, en son vivant de Montréal, décédé le 31 mai 1973.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boulevard St-Laurent, Montréal (Que.) H2N 1N6 60700-0 Estate of Henry Ferguson Estate of the late Ferguson, Henry, in his lifetime of Montreal, deceased May 31st, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971) he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2N 1N6 60700-o Succession Léonidas Glaude Succession de Glaude, Léonidas, en son vivant de Montréal, décédé le 10 septembre 1974.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boulevard St-Laurent, Montréal (Que.) H2N 1N6 60701-o Estate of Léonidas Glaude Estate of the late Glaude, Léonidas, in his lifetime of Montreal, deceased September 10th, 1974.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2N 1N6 60701-o 3586 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.18 Succession Andrew F.Horan Succession de Horan, Andrew F., en son vivant de Montréal, décédé le 19 septembre 1974.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal (Que.) H2N 1N6 60702-o Succession Rranko Hrdlicka Succession de Hrdlicka, Branko, en son vivant de Montréal, décédé le 19 août 1974.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal (Que.) H2N 1N6 60703-o Succession Steve Kolody Succession de Kolody, Steve, en son vivant de Montréal, décédé le 1er mai 1973.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent.Montréal (Que.) H2N 1N6 60704-o Succession Dora Luinsden Succession de Lumsden, Dora, en son vivant de Montréal, décédée le 12 mai 1973.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent.Montréal (Que.) H2N 1X6 60705-o Estate of Andrew F.Horan Estate of the late Horan, Andrew F., in his lifetime of Montreal, deceased September 19th, 1974.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator op Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2N 1N6 60702-o Estate of Branko Hrdlicka Estate of the late Hrdlicka, Branko, in his lifetime of Montreal, deceased August 19th, 1974.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2N 1X6 60703-o Estate of Steve Kolody Estate of the late Kolody, Steve, in his lifetime of Montreal, deceased May 1st, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2N 1X6 60704-o Estate of Dora Lumsden Estate of the late Lumsden, Dora, in her lifetime of Montreal, deceased May 12th, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof o:' any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2X 1X6 60705-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1975, 107' année, n° 18 3587 Succession Georges Park Succession de Park, Georges, en son vivant de Montréal, décédé le 30 juillet 1974.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971.chap.81).qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public pv Québec.9310.boul.St-Laurent.Montréal (Que.) H2N 1X6 60706-o Estate of Georges Park Estate of the late Park, Georges, in his lifetime of Montreal, deceased July 30th, 1974.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971).he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2X 1X6 60706-o Succession Joseph Robillard Succession de Robillard.Joseph, en son vivant de Montréal, décédé le 26 septembre 1974.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310.boul.St-Laurent, Montréal (Que.) H2X 1X6 60707-o Succession Lucien Galarneau Succession de Galarneau, Lucien, en son vivant de Montréal, décédé le 5 juillet 1973.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent.Montréal (Que.) H2X 1X6 60708-o Succession Robert Stellard Succession de Stellard, Robert, en son vivant de Montréal, décédé le 8 mars 1973.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal (Que.) H2X 1N6 60709-o Estate of Joseph Robillard Estate of the late Robillard, Joseph, in his lifetime of Montreal, deceased September 26th, 1974.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2X 1X6 60707-o Estate of Lucien Galarneau Estate of the late Galarneau, Lucien, in his lifetime of Montreal, deceased July 5th, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2X 1X6 60708-o Estate of Robert Stellard Estate of the late Stellard, Robert, in his lifetime of Montreal, deceased March 8th, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 Saint-Laurent Blvd., Montreal (Que.) H2X 1X6 60709-o 3588 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.IS Proclamation Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que, sous l'autorité de l'article 2 de la Loi des titres de propriété dans certains districts électoraux (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 321), le ministre des terres et forêts a fait dresser des plan et livre de renvoi revisés, dans le district électoral de Saguenay, pour le cadastre d'une partie du canton De Monts, à l'endroit des lots 1 à 4, 7, 11 à 30, 34 à 55, 76, 97 à 161, le bloc O et les lots 1 à 31 du bloc S de Baie-Trinité-Est, les lots « A » et « B » de la rivière Grande-Trinité, le lot « A » côté nord de l'embouchure de la rivière Grande-Trinité et l'île numéro 15 des îles du golfe Saint-Laurent et de leurs subdivisions respectives, le tout situé dans la division d'enregistrement de Saguenay; Attendu que, conformément aux articles 2 et 3 de ladite Loi, le ministre des terres et forêts a fait déposer: 1.le 18 novembre 1974, aux archives du ministère des terres et forêts, à Québec, ces plan et livre de renvoi; 2.le 21 novembre 1974, au bureau de la division d'enregistrement de Saguenay, à Baie-Comeau, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi; 3.le 20 novembre 1974, au bureau désigné par lui, à savoir celui du secrétaire-trésorier de la corporation municipale du village de Baie-Trinité, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi; Attendu Qu'il y a maintenant lieu d'émettre la proclamation prévue à l'article 4 de ladite Loi.A ces causes, du consentement et de l'avis de Xotre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 896-75, du 5 mars 1975, Xous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi des titres de propriété dans certains districts électoraux (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 321), qu'il y a lieu : a) de fixer à la date de la deuxième et dernière publication consécutive de cette proclamation dans la Gazette officielle du Québec, l'entrée en vigueur des plan et livre de renvoi révisés, dans le district électoral de Proclamation Canada, Province of HUGUES LAPOIXTE Québec.(L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas, under the provisions of section 2 of Certain Electoral Districts Land Titles Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 321), the Minister of Lands and Forests has caused to be drawn up a revised plan and book of reference in the Electoral District of Saguenay, for the cadastre of a part of the Township of De Monts, with regard to lots 1 to 4, 7, 11 to 30, 34 to 55.76, 97 to 161, block O and lot 1 to 31 of block S in Baie-Trinité-East, lots \"A\" and \"B\" of the Grande-Trinité River, lot \"A\" north side of the mouth of the Grande-Trinité River and Island number 15 of the islands of the Gulf of St.Lawrence and their respective subdivisions, the whole located in the Saguenay Registration Division; Whereas, in conformity with sections 2 and 3 of said Act, the Minister of Lands and Forests has caused to be deposited : 1.on November 18, 1974 in the Archives of the Department of Lands and Forests, in Québec, this plan and book of reference; 2.on November 21, 1974 in the Saguenay Registration Division Office, in Baie-Comeau, a certified copy of said plan and book of reference; 3.on November 20, 1974 in the office designated by him, namely that of the Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of the Village of Baie-Trinité, a certified copy of said plan and book of reference; Whereas it is now expedient to issue the proclamation provided for in section 4 of said Act.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 896-75, dated March 5, 1975, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and in conformity with sections 2.3, 4 and 5 of the Certain Electoral Districts Land Titles Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 321), that it is expedient: (a) To fix the date of the second and final consecutive publication of this proclamation in the Québec Official Gazette as the date of the coming into force of the revised plan and book of reference, in the Electoral GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1975, 107' année, n\" 18 3589 Saguenay, pour le cadastre d'une partie du canton de De Monts, à l'endroit des lots 1 à 4, 7, 11 à 30, 34 à 55, 76, 97 à 161, le bloc O et les lots 1 à 31 du bloc S de Baie-Trinité-Est, les lots « A » et « B » de la rivière Grande-Trinité, le lot « A » côté nord de l'embouchure de la rivière Grande-Trinité et l'île numéro 15 des îles du golfe Saint-Laurent et de leurs subdivisions respectives, le tout situé dans la division d'enregistrement de Saguenay; b) d'indiquer que ces plan et livre de renvoi révisés sont déposés aux archives du ministères des terres et forêts, à Québec, et, qu'en outre, le ministre des terres et forêts a fait déposer une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi revisés au bureau de la division d'enregistrement de Saguenay, à Baie-Comeau, ainsi qu'au bureau désigné par lui, à savoir celui du secrétaire-trésorier de la corporation municipale du village de Baie-Trinité.c) d'informer le public que, pendant les huit mois (8) qui suivront la deuxième et dernière publication de cette proclamation dans la Gazette officielle du Québec, tout intéressé pourra consulter gratuitement lesdits plan et livre de renvoi revisés; d) porter notification qu'à l'expiration de ce délai, le ministre des terres et forêts délivrera un certificat de propriété à tout occupant de l'immeuble avec ou sans titre, même s'il n'est qu'administrateur ou simple exploitant, à moins d'opposition écrite d'un intéressé; e) d'ordonner que tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire susdit pour lequel un plan et un livre de renvoi revisés ont été déposés soit renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par les articles 2172 à 2172a du Code civil; /) d'informer aussi le public que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce cinquième jour de mars en l'année mil neuf cent soixante-quinze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-quatrième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Libro: 502 René L angevin.Polio: 85 60691-18-2-o District of Saguenay, for the cadastre of a part of the Township of De Monts, with regard to lots 1 to 4, 7, 11 to 30, 34 to 55, 76, 97 to 161, block O and lots 1 to 31 of block S of Baie-Trinité-East, lots \"A\" and \"B\" of the Grande-Trinité River, lot \"A\" north side of the mouth of the Grande-Trinité River and island number 15 of the islands of the Gulf of St.Lawrence and their respective subdivisions, the whole located in the Saguenay Registration Division; (b) To state that the said revised plan and book of reference have been deposited in the Archives of the Department of Lands and Forests, in Québec, and that moreover, the Minister of Lands and Forests has caused a certified copy of said revised plan and book of reference to be deposited in the Saguenay Registration Division, in Baie-Comeau, as well as in an office designated by him, namely that of the Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of the Village of Baie-Trinité; (fi) To inform the public that during the eight months following upon the second and final publication of this proclamation in the Québec Official Gazette, any interested party may consult, without charge, the said revised plan and book of reference; (d) To give notice that when such time limit expires, the Minister of Lands and Forests will issue a certificate of ownership to any occupant of the immoveable, with or without title, even though he be only an administrator or an operator of such immoveable, unless an interested party objects in writing; (e) To order that any real right affecting a lot comprised in the aforesaid territory for which a revised plan and book of reference have been deposited be renewed, within the same period, in the manner prescribed by articles 2172 and 2172a of the Civil Code; (/) Also to inform the public that, failing such renewal, the real rights preserved by the first registration shall have no effect as regards other creditors or subsequent purchasers whose rights are duly registered.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this fifth day of March in the year of Our Lord, one thousand nine hundred seventy-five and in the twenty-fourth year of Our Reign.By command, René Langevin, Libro: 502 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 85 60691-18-2 3590 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.May 3.1975, Vol.107, No.18 Commission des transports du Québec Québec Transport Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu > (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.[I \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées, i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regu- lation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1975,10T année, n° 18 3591 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.* Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(c) Verification of permits.(d) Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.(e) * Special permits.* In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.Catégorie Class Sous-catégories Sub-classes Codes Montréal Québec Couleurs Numéros de dossiers Colours File numbers Transport public Public transport Transport général General trucking Location Leasing Transport spécialisé Specialized transportation Voyageur MPV QPV Passenger Écolier MPE QPE Student Taxi MPT QPT Taxicab Camionnage régulier MCR QCR Regular trucking Camionnage spécialisé MCS QCS Specialized trucking Transport en vrac MCV QCV Bulk transportation Location ML QL Leasing Maritime MSM QSM Water Aérien MSA QSA Air Ferroviaire MSF QSF Rail Rose Pink Rouge foncé Dark red Jaune orange Orange Orange brûlé Burnt orange Vert pâle Light green Vert foncé Dark green Bleu pâle Light blue Bleu foncé Dark blue Mauve M auve Brun Brown M 000001 Q 000001 M 100001 Q 100001 M 200001 Q 200001 M 300001 Q 300001 M 400001 Q 400001 M 500001 Q 500001 M 600001 Q 600001 M 700001 Q 700001 M 800001 Q 800001 M 900001 Q 900001 à M 002000 à Q 001000 à M 103000 àQ 102000 à M 210000 àQ 205000 à M 303000 àQ 302000 à M 402000 àQ 401000 à M 504000 àQ 503000 à M 601000 à Q 600500 à M 700500 à Q 700500 à M 800500 à Q 800500 à M 900500 à Q 900500 MPV \u2014 Montréal transport public \u2014 voyageurs / Montreal public transport \u2014 passengers QPV \u2014 Québec transport public \u2014 voyageurs / Québec publie transport \u2014 passengers MPE \u2014 Montréal transport public \u2014 écoliers / Montreal public transport \u2014 students QPE \u2014 Québec transport public \u2014 écoliers / Québec public transport \u2014 students MPT \u2014 Montréal transport public \u2014 taxi / Montreal public transport \u2014 taxicab QPT \u2014 Québec transport public \u2014 taxi / Québec public transport \u2014 taxicab MCR \u2014 Montréal transport régulier \u2014 camionnage / Montreal regular transportation \u2014 trucking QCR \u2014 Québec transport régulier \u2014 camionnage / Québec regular transportation \u2014 trucking QVEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 197-0.Vol.107, So.18 MCS \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 camionnage / Montreal specialized transportation \u2014 trucking QCS \u2014 Quebec transport spécialisé \u2014 camionnage / Québec specialized transportation \u2014 trucking MCV \u2014 Montréal transport en vrac \u2014 camionnage / Montreal bulk transportation \u2014 trucking QCY \u2014 Québec transport en vrac \u2014 camionnage / Québec bulk transportation \u2014 trucking ML \u2014 Montréal location / Montreal leasing QL \u2014 Québec location / Québec leasing MSM \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 maritime / Montreal specialized transportation \u2014 water QSM \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 maritime / Québec specialized transportation \u2014 water MSA \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 aérien / Montreal specialized transportation \u2014 air QSA \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 aérien / Québec specialized transportation \u2014 air MSF \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Montreal specialized transportation \u2014 rail QSF \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Québec specialized transportation \u2014 rail I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu»: La Commission donne avis qu'elle entend décider des affaires suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Ouiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.| \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission: The Commission gives notice of its intention to seule the following proceedings in conformity with Ihe provisions of section 2.24 of Regulation 2.Whoever wishes lo be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publics ion.Rôle 0-M93 O-200904-P-1 LÉO GAGNON 408, rue Ste-Anne Chicoutimi tOué.l Rôle M-8046 22772-V-P-2 CAN-AM MARINE TRANSIT LTD.Main Road.P.O.Box 790 Hudson (Vaudreuill (Oué.) Mise en cause Aux tins de: 1.verifier le permis détenu relativement à son exploitation et au paiement des droits relativement au transfen des permis et au renouvellement des permis; 2.réviser aux fins de les révoquer, s'il y a lieu, les décisions numéros OPT-3019.OPT-3020 el OPT-3021 rendues par ta Commission le 18 février 1975.Aux fins de combler une omission qui s'esi produite dans la décision du permis spécial MS-1368.MRS-0915 du 10 mar, 1975.émis à la compagnie mise en cause, laquelle décision n'incluait pas les provisions du d-oil addilionel.demandé, tel que décrit ci-aprcs: Droit additionnel: La panic requérante s'adresse à la Commission des transpons du Québec dais le but d'obtenir l'auiorisation de louer cl tirer avec ses tracteurs, les remorques de Performance Sailcrafl Inc.pour iransponer les marchandises de cette dernière et Performance Sailcial't Inc.pourra louer à Can-Am Marine Transit Ltd.ses remorques pour les mêmes fins.Ce droit additionnel s'applique à toutes les clauses du permis no 22772-V de Can-Am Manne Transit Lld.Vu les services additionnels des clauses e el I accordés à Can-Am Marine Transit Ltd.dans la décision de la Commission no MCS-98J datée du 28 janvier 1975.requèle no 22772-V-D-3.rôle M-3588.il esl à noter que le droit additionnel susmentionné devrait également s'appliquer à ces deux nouveaux services des clauses e et I qui ne furent pas récitées dans le permis spécial du 10 mars 1975.For the purpose of: 1.verifying the permit held as regards its operation and (he payment of dunes regarding the transfer and renewal of permits: 2.revising decisions numbers OPT-3019.OPT-3020 and OPT-3021 rendered by Ihe Commission on February 18.1975.and revoking them, if need be.For Ihe purpose of rectifying an omission in Ihe decision with regard lo special permit MS-1368.MRS-0915.dated March 10.1975.issued in behalf of Ihe company mise en cause: said decision failed lo include Ihe provisions of the additional right requested, as described hereinafter: Additional right: The applicant requests from the Ouébec Transpon Commission authorization lo lease, and lo haul, with ils tractors, the trailers belonging to Performance Sailcrafl Inc.lor the transpon of the laiter's goods.Performance Sailcrafl Inc.shall be authorized to lease its nailers to Can-Am Marine Transit Ltd.lor the same purposes.This additional right shall apply to all the clauses of permit No.22772-V ol Can-Am Marine Transit Ltd.Considering the additional services clauses e and J.and granted 10 Can-Am Marine Transit Ltd.bv the Commission's decision No.MCS-983.dated January 28.1975.application No.22772-V-D-3.Roll M-3588.ii is io be noted that the jfoicmenhoncd additional richt shall also apply lo these two nevv services described in clauses i' and/, which clauses were not requested in the special permit dated March 10.1975. O.tXETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC, .) mai 1975, 307' année, u' 1S 3593 Rôle M-8090 M-205674-D-00I PAQUETTE, VICTOR CP.85 Lac-des-Ecorces (Labellel (Oué.) Aux fins de corriger la décision MPT-7473 de la cause MT-6973 en dale du 17 juillei 1974 pour qu'elle se lise Lac-des-Ecorces 07-7636-V ei non Labelle 06-7607-SD.For Ihe purpose of correcting decision MPT-7473 regarding case MT-6973, daled July 17.1974, by substituting \"Lac-des-Ecorces 07-7636-V\" lor \"Labelle 06-7607-SD\".Rôle M-8091 Aux fins de corriger la décision MPT-689 For the purpose of correcting decision MPT- M-20434I-D-I de la cause MT 0189 en date du 17 juin 1974 689 regarding case MT-0189.daled June GRENIER LIGUORI pour qu'elle se lise Mont-Laurier 07-7640-VT 17.1974.by substituting \"Mont-Laurier 851 Des Carrières et non Labelle 06-7607-SD.07-7640-VT\" for \"Labelle 06-7607-SD\".Mont-Laurier (Oué.) Rôle M-8092 M-205638-D-00I PAQUETTE, ANTONIO Lac-des-Ecorces (Labelle) (Oué.) Aux fins de corriger la décision MPT-697 de la cause MT-0197 en date du 17 juin 1974 pour qu'elle se lise Lac-des-Ecorces 07-7636-V et non Labelle 06-7607-SD.For the purpose of correcting decision MPT-697 regarding case MT-0197.dated June 17.1974.by substituting \"Lac-des-Ecorces 07-7636-V\" for \"Labelle 06-7607-SD\".60690-0 II \u2014 Avis d'introduction de requêtes: La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.II \u2014 Notices of submission of applications: The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of sec-lion 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes lo object or lo intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.Rôle 0-3441 23782-V-D-3 PERRON, VICTORIEN 2720.rue St-Georges Giffard (Oué.) Modification de permis: La partie requérante désire être autorisée à donner le service de transport suivant: Transpon restreini - longue distance - route restreinte - véhicule citerne - De Beloeil à la frontière Ouébec-Ontario (poste d'entrée: Rivière-Beaudette el/ou Pointe-Fortune) pour le transport d'explosifs liquides dans des véhicules citernes, destination: Calgary (Alberta).Droit additionnel: En donnant ce service la délentrice a le droit d'utiliser des véhicules citeincs qui sont la pio-priélé de la compagnie Canadian Industries Limited, ou qui sont loués par cette compagnie.Modification of permit: The applicant wishes to be authorized lo provide the following transport service: Restricted transpon - long distance - restricted route - lank véhicule - From Beloeil lo Ihe Ouébec-Onlario border (port of entry: Rivière-Beaudelte and/or Pointe-Fortune) for the transport of liquid explosive by tank véhicule, destination: Calgary.Alberta.Additional right: In performing this service the permit-holder shall have the right lo use lank vehicles owned or rented by Canadian Industries Limited.Rôle 0-3442 956-DY-D-l-TF PREMIER DRIVE YOURSELF INC.854.boul Laure Sept-lles (Oué.) La requérante demande à la Commission des transpons du Ouébec l'autorisation d'augmentei ses tarifs afin qu'ils se lisent à l'avenir comme suit: $23 par jour.100 milles gratuits par jour; $6 par heure.25 milles gratuits par heure additionnelle: $161 pa- semaine.700 milles gratuits par semaine; $600 par mois.2.400 milles gratuits par mois; $0.16 par mille, tout millage additionnel.Tous les taux ne comprennent pas la gazoline.The applicant requests from the Ouébec Transpon Commission authotization to increase Us tariffs so lhal they read henceforth as follows: $23 per day.100 free miles per day: $6 per hour.25 free miles per additional hour: $161 per week.700 free miles per week: $600 per month.2.400 free miles per month; $0.16 per mile, all additional mileage.All tales do not include gasoline. QUÉBEC OFF ICI Al.GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.IS Rôle 0-3443 24209-V-D-1 BANVILLE, RODRIGUE 7, avenue du Parc Matagami (Oué.) el / and 6793-V BRAZEAU TRANSPORT INC.380.rue Burke Rouyn (Oué.) Rôle 0-3444 O-501560-D-002 ALPHONSE MORNEAU Sl-Pamphile (L'lslet) (Oué.) Nouvelle demande: Transpon par remorquage - conlral -Demande esi faite d'autoriser Rodrigue Banville à lirer avec ses Iracleurs dûmenl enregislrés les remorques de Brazeau Transport Inc.permis no 6793-V selon les clauses c à c.au à ce.aaa à fff dudil permis no 6793-V.Le requéranl, qui possédail un camion au 14 avril 1972.demande un permis de camionnage en vrac, dans la région no 3.de calégorie Entrepreneur.New application: Haulaway transportation - contract -The Commission is requested to authorise Rodrigue Banville lo haul, with its duly-registered tractors, the trailers of Brazeau Transport Inc.permit No.6793-V accoiding lo clauses c 10 z.aa lo zz.aaa lo fff of said permit No.6793-V.The applicant, who owned a truck on April 14.1972.requests a bulk trucking permit, Con-tractor class, for Region No.3.Rôle 0-3445 242I3-V-D-I CALFAX CRANE SERVICE LIMITED 639, Windwill Road Darmouth Nouvelle-Ecosse Ouébec: BEAUDRY McNICOLL & TANGUAY 105.Côte de la Montagne (Oué.) GIK 4E4 Rôle 0-3446 13340-V-D-1 GUERTIN & FILS LIMITÉE 1085.avenue Larivière BP.125 Rouyn (Oué.) J9X 4K9 el / and 6793-V BRAZEAU TRANSPORT INC.380.rue Burke Rouyn (Oué.) Nouvelle demande: Lu partie requéranle demande a la Commission des tiansports du Ouébec l'autorisation de donner le service de transport suivant: Transport restreint - longue distance - route restreinte - contrai - De la frontière Ouébec-Nouveau-Brunswick (tous les ports d'entrée) à Val-Alain, province de Ouébec.et retour.Transport restreint - longue distance - route restreinte - « in transit » - conlral - , De la frontière Ouébcc-Nouveau-Brusnwick (tous les ports d'entrée)«in transit» à travers la province de Ouébec à la frontière de la province d'Ontario (tous les ports d'entrée);\"et retour.Concernanl le transport de matériaux lourds et de fournitures, incluant des pioduits de fei el d'acier, constituant l'équipement utilisé dans le champ et le développement de I' ndustrie pétro-lifère.par des véhicules équipés ou non de grues, à partir de points situés en Nouvelle-Ecosse, origine de ces marchandises.Le prix de ce transport est défrayé par les trois compagnies suivantes: Schlumbergcr Canada.42 Fielding Avenue.Darmouth, N.S.East Coast Oilfield Service and Supply Lid.639 Windwill Road.Darmouth.N.S.Soquip.3340.de la Pérade.Ste-Foy.Ouébec 10.La marchandise ainsi transportée est la propriété de ces trois compagnies.Service additionnel: Transpon par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Guertin & Fils Limitée à tirer avec ses tracteurs cûment enregislrés les remorques de Brazeau Transport Inc.(6793-V).selon les clauses < à fff dudit permis no 6793-V.New application: The applicant requests from Ihe Ouébec Transport Commission authorization lo provide Ihe following transport service: Restricted trucking - long dislance -restricted route - contraci - From the Ouébec-New Brunswick border (all ports of entry) to Val-Alain.Province of Ouébec, and return.Restricted trucking - long distance -restricted route - \"in transit\" - contract - From the Ouébec-New Brunswick border (all ports of enliy) in transit through the Province of Ouébec to Ihe Ontario border (all ports of entry), and return.Regarding the transport of heavy materials and supplies, including iron and steel products which constitute Ihe equipment used in Ihe field and development of the pelioleum industry, in vehicles, whether equipped or not with cranes, from points located in Nova Scotia, where said goods originate.The cost of this transport shall be paid lor by the following three companies: Schulcmberger Canada.42 Fielding Avenue.Darmouth.N.S.East Coast Oilfield Service and Supply Ltd.639 Windwill Road.Darmouth.N.S.Soquip.3340.de la Pérade.Ste-Foy.Ouébec 10.The goods thus transported is the property of these three companies.Additional service: Haulaway transportation - contract-The Commission is requested to authorize Guertin & Fils Limitée to haul, with its duly-registered tractors, the trailers of Brazeau Transport Inc.(6793-V).according to clauses c to fff of said permit No.6793-V. (UZÊTTE OFFICIELLE DC Ql'I-IIEC.-I mai 1970, 101' année, n\" IS 3595 Rôle 0-3447 24215-V-D-1 LES HL'ILES MONTCALM INC.MONTCALM OIL INC.30.boul.Wilfrid-Hamel (Que.) Nouvelle demande: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec le permis de transport suivant: Transport restreint - service local -De Ouébec à tout autre endroit situé à une distance de cinq 15) milles ci retour, pour le transport de produits pétrolifères.Transpon restreint - longue distance - rayon -De Ouébec à tout autre endroit situé dans un rayon de trente (30) milles et retour, pour le transport de produits pétroliléres pour plus d'un expéditeur par voyage le cas échéant.New application: The applicant requests from the Ouébec Transport Commission a permit lor the following transport service: Restricted trucking - local service -From Ouébec City to any othei point located within a distance of five (5) miles from said City and return, for the transport of petroleum products.Restricted trucking - long dislance - radius -From Ouébec City lo any other point located within a radius of thirty (30) miles from said Cily and return, for the Iransport of petroleum products for more than one shipper on any one trip if necessary.Rôle 0-3448 O-504535-D-00I ROSAIRE BOUCHARD 232.Joseph-Garon Rimouski (Oué.) Le requérant, qui possédail un camion au 14 avril 1972, demande un permis de camionnage en vrac, de catégorie Artisan, pour la région no I.The applicant, who owned a truck on April 14, 1972.requests a bulk Irucking permit.Artisan class, for Region No.1.Rôle 0-3449 O-504482-D-00I J.A.PERRON & FRÈRES ENRG.Rivière-à-Pierre (Portneuf) (Oué.) Rôle 0-3460 O-20I207-D-3 JACQUES LEPAGE Sle-Anne-des-Monls (Gaspéi (Oué.) Le requérant, qui possédai! un camion au 14 avril 1972.demande à la Commission un permis de camionnage en vrac, dans la région no 3.de catégorie Entrepreneur.Requête en révision Dossiers no: O-20I207-D-I O-20I207-D-2 O-20I207-P-I A la suite de ma lettre du 20 mars 1974.un «proprio motu » a été fait par la Commission aux fins d'annuler le permis no O-20I207-D-2.dû au fait que j'avais vendu le véhicule pour lequel le permis était annulé.Le fait relaté au paragraphe 1 est dû à ce que je ne connaissais pas les numéros de dossiers et de permis se rapportant au véhicule que j'ai vendu, ainsi je me suis départi d'un véhicule et c'est le permis de l'autre véhicule, pour lequel je détiens un permis, qui a été annulé.Plaise à la Commission de réviser le «proprio motu» du 8 novembre 1974.pour annuler le permis véritable pour lequel j'ai vendu le véhicule sou le permis no O-20I207-D-I.The applicant, which was the owner of a truck on April 14.1972.requests from the Commission a bulk trucking permit.Contractor class, for Region No.3.Request for a revision Files Nos.: O-20I207-D-I O-20I207-D-2 O-20I207-P-I Further to my letter dated March 20.1974.a \"proprio motu\" notice was given by Ihe Commission, lo cancel permit No.O-20I207-D-2.owing to Ihe fact that I had sold the vehicle for which this permit had been issued.The silualion described in paragraph I is due to the fact that I did not know the numbers ot the file and permit relating lo the vehicle thai I sold.Therefore, the permit thai was cancelled was ihe one attaching to the vehicle that I still own.instead of the one attaching to Ihe vehicle lhat I sold.May it please the Commission lo revise the \"proprio motu\" notice daled November 8.1974.in order to cancel the actual permit attaching to the vehicle that I sold, namely permit No.O-20I207-D-I.Rôle 0-3462 O-20047-D-I LA LIGUE DE TAXIS DE MAT AGAMI INC.a/s Robert Beauregard 6.rue Câlinée.CP.1322 Matagami (Oué.) JOY 2A0 Rôle 0-3463 O-202I82 MARCEL CAUCHON 12.rue Laplante Chateau-Richer (Que.) La requérante demande d'être reconnue comme le comité représentatif des détenteurs de permis de propriétaires pour l'agglomération A-47, Matagami.Le requérant demande à la Commission un permis de propriétaire pour effectuer du Iransport par véhicule-taxi dans la région ou la municipalité de Château-Richer.The applicant requests recognition as the representative committee of holders of owners' permits for Conglomeration A-47.Matagami.The applicant requests from the Commission an owner's permit lo effect transport by taxicab in the Region or Municipality of Chateau-Richer. QCKUEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 19,5, J'ol.107, So.18 Rôle 0-3464 O-202I28 JEAN-GUY DORÉ 187.rue Si-Jacques Donnacona (Oué.) Rôle 0-3469 53-A-D-S AUTOBUS ALPHONSE DROLET LTÉE 2270.Noire-Dame Sle-Foy (Oué.) Rôle 0-3471 3578-A-D-2 MARIO CHIASSON C.P.53.Bessin Iles-de-la-Madeleine (Oué.) Rôle 0-3472 I75I-A-D-1-TF AUTOBUS LEVIS INC.139.rue Commerciale Lévis (Oué.) Le requérant demande à la Commission des iransports du Ouébec un permis de propriétaire pour effectuer du transport par vehicule-taxi dans la région suivante: la municipalité de Donnacona.Modification de service: Classe: Autobus.Service: La requérante s'adresse à la Commission des transports du Ouébec pour obtenir une modification du permis 53-A.de façon a faire lever la restriclion A: «Pas de service local sur le parcours Clermont-La Malbaie >.attachée à son service de transport en commun no 2: service de Ouébec à Baie-Comeau et rclour.Droits addilionnels: Classe: Aulobus.Service: Le requéiant demande à la Commission des transports du Ouébec d'être autorisé à transporter des personnes par minibus, de tout point sur le territoire des Iles-de-la-Madeleine à tout point situé à l'intérieur de ce même territoire.La requérante demande à la Commission des transports du Ouébec l'autorisation d'augmenter ses tarifs pour le transport de passagers en vertu du permis qu'elle détient.Les taux proposés sont les suivants: Taux proposés: 1.Circuit Lévis el Lauzon-St-David: Adultes: en espèce.$0.35 en série .10 x 3.00 5 x 1.50 Enfants: en espèce.0.25 en série .10 x 2.00 2.Circuit Lévis-St-Romuald-Ste-Foy-Qué-bec: Aller: Lévis pour St-Romuald.$0.60 Lévis pour Ste-Foy.0.90 Lévis pour Ouébec.1.20 3.Circuit St-Romuald: St-Romuald.$0.30 St-Romuald-Ouébec .0.90 Sl-Romuald-Ste-Foy.0.60 4.Circuit Charny: Aller: Charny.$0.30 Chainy-Ouébec.0.90 Charny-Ste-Foy.0.60 Charny-St-Romuald .0.30 Charny-Lévis.0.60 5.Circuit Breakeyville: Breakeyville-Ouébec.$1.20 Brcakcyvillc-Charny.0.30 Brcakeyville-St-Romuald.0.60 Breakeyville-Sle-Foy .0.90 6.Circuit St-Lambert: Si-Lamben-Ouébec.$1.50 St-Lamben-Breakeyville.0.60 St-Lambert-Charny.0.75 St-Lambert-St-Romuald .0.90 The applicant requests trom the Ouebec Transport Commission an owner's permit lo effeci transport by taxicab in ihe following Region: the Municipality of Donnacona.Modification of services: Class: Bus.Service: The applicant requests from the Ouébec Transpon Commission a modification of permit 53-A, in order lo remove restriction A: \"No local service on the Clermont-La Malbaie route\", said restriclion attaching to its public transpon service No.2: service from Ouébec City lo Baie-Comeau and return.Additional rights: Class: Bus.Service: The applicant requests from the Ouébec Transport Commission authorization to transport persons by minibus, from any point located on the Magdalen Islands territory to any other point located within this same territory.The applicant requests from the Ouébec Transport Commission authorization to increase its tariffs for the transport of passengers by virtue of its permit.The proposed rates are the following: Proposed rates: 1.Levis and Lauzon-St-David Route: Adults: Cash fare.$0.35 Tickets.10 x 3.00 5x 1.50 Children: Cash fare.0.25 Tickets.10 x 2.00 2.Lévis-St-Romuald-Sie-Foy-Québec Route: One-way trip: Levis lo St-Romuald.$0.60 Levis to Ste-Foy.0.90 Lévis lo Québec .1.20 3.Sl-Romuald Route: St-Romuald.$0.30 St-Romuald-Ouébec .0.90 St-Romuald-Ste-Foy.0.60 4.Chamy Route: One-way (rip: Charny.$0.30 Charny-Québec.0.90 Charny-Ste-Foy.0.60 Charny-Sl-Romuald .0.30 Charny-Lévis.0.60 5.Breakeyville Route: Breakeyville-Ouébec.$1.20 Breakeyville-Charny.0.30 Breakeyville-St-Romuald.0.60 Breakeyville-Stc-Foy .0.90 6.St-Lamben Route: Sl-Lambert-Ouébec.$1.50 Sr-Lambert-Breakeyville.q.60 St-Lamben-Charny.0.75 St-Lambert-St-Romuald .Q.90 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1975.107' année, n\" 18 3597 7.Circuit.St-Jean: St-Jean-Québec.$1.20 St-Jean-Ste-Foy.0.90 St-Jean-Sl-Romuald .0.30 St-Jean-Lévis.0.60 7.Sl-Jcan Route: St-Jean-Québec.$1.20 St-Jean-Ste-Foy.0.90 St-Jean-St-Romuald .0.30 Sl-Jean-Lévis.0.60 Rôle 0-3473 I5729-V-D-2-TF LEMIEUX & TREMBLAY LTD.CP.69.Mont-Louis (Gaspé) (Oué.) Rôle 0-3474 18059-V-D-1 DOUVILLE, FERNANDO 256.rue Principale Sl-S(anislas (Champlain) (Oué.) La requérante demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation d'augmenter ses tarifs pour le transport de mazout (Bunker «C» Oil) de Mont-Louis à Murdochville: Taux actuels: $2.60 la tonne.Taux proposés: $2.80 la tonne.Modification de permis: La partie requérante détentrice d'un permis dont la clause b se lit comme suit: b) Transport restreint - longue distance -rayon - fardier - b) De tous points situés dans un rayon de 25 milles de Si-Stanislas à ailleurs dans la Province et retour, pour le transport, par fardier, de machinerie lourde.Conditions et restrictions: 1.En donnant le service décrit à la clause b.le détenteur n'est pas autorisé à donner un service de Shawinigan et de Shawinigan-Sud à tout endroit situé en dedans d'un rayon de 30 milles de ces endroits.2.Le transport autorisé par ce permis est limité à la marchandise lourde qji.à cause de sa nature, grosseur, pesanteur ou forme ne peut être transportée qu'à l'aide d'un fardier.ainsi que des pièces s'y rattachant, du matériel et de l'équipement d'entrepreneurs et de fournitures, dont le transport se rattache au transport de ladite machinerie lourde.Il incombera au détenteur de démontrer, à la satisfaction de la Commission, que les machineries lourdes et les objets s'y rattachant, qu'il transportera, ne peuvent normalement être transportés par un détenteur de permis de camionnage général, et que ce dernier ne fournit pas habituellement l'équipement que ce genre de transport requiert.Demande que la susdite clause soit modifiée pour se lire à l'avenir comme suit: Transpon restreint - longue distance - rayon -fardier - De tous points situés dans un rayon de 25 milles de St-Stanislas à ailleurs dans la province, et retour, pour le transport, par fardier.de machinerie lourde, cabanes à pèche, caissons, réservoirs, équipement lourd et en général tous objets qui, a cause de leur nature, grosseur ou forme ne peuvent être transportés qu'à l'aide d'un fardier.Conditions et restrictions: Les conditions et les restrictions habituelles au transport par fardier s'appliqueront.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization lo increase its tariffs for the transport of fuel oil (Bunker \"C\" oil) from Mont-Louis lo Murdochville: Present tales: $2.60 per ton.Proposed rates: $2.80 per Ion.Modification of permit: The applicant, holder of a permit whose clause b reads as follows: (b) Restricted trucking - long dislance -radius - float - (/>) From all points located within a radius of 25 miles from St-Stanislas to elsewhere in the Province, and return, for the transport, by float, of heavy machinery.Conditions and restrictions: 1.When providing the service described in clause b.the holder shall not be authorized lo provide a service from Shawinigan and Shawinigan-South to any point located within a radius of 30 miles from these points.2.The transport authorized by this permit shall be restricted to heavy objects which, because of then nature, size, weight or shape require the use of a float, and for the transport of related parts, and contractors' equipment, material and supplies the use of which is incidental to the transport of said heavy machinery.It shall be the responsibility of the holder to prove lo the satisfaction of the Commission that the heavy machinery and parts thereof, which Ihe holder will transport, cannot normally be transported by the holder of a general trucking permit, and that the equipment required for this lype of transport is not customarily provided by Ihe holder of such a permit.Requests thai Ihe aforesaid clause be modified to read hencelorth as follows: Restricted trucking - long distance -tadius - float - From any point located within a radius of 25 miles from St-Stanislas lo any other point in the Province, and return, for the transport, by float, of heavy machinery, fishing cabins, boxes, tanks, heavy equipment and any objects which, because of their nature, size or shape, generally require the use of a float.Conditions and restrictions: The conditions and restrictions usually applicable to the transport by float shall apply.Rôle Q-3477 8642-V-D-3 GOSSELIN EXPRESS LTÉE/LTD.141.boul.Smith Sud Thetford Mines (Que.) Modification de permis (clauses h, s.I): La partie requérante; détentrice du permis numéro 8642-V, dont les clauses h.s et / se lisent comme suit: h) Transport restreint - longue dislance -rayon -_ n) De Thetford Mines et Black Lake à tous les endroits situés dans les provinces de Québec, pour le transport de lenles-roulottes et roulottes Modification of permit (clauses h.s./): The applicant, holder of permit number 8642-V.whose clauses h, s and I read as follows: (h) Restricled trucking - long dislance - radius - (h) From Thetford Mines and Black Lake to all points located in the Province of Québec, for Ihe transpon.by lowbed trailer, of trailer tents QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 3.107Ô, Vol.107, .Vo.IS originant des usines d A pa lâche Industries Lid.el Tentes Mobiles Inc.dc Therford Mines, ainsi que des usines de Tenles Contort Inc.de Black Lake, avec remorques surbaissées, el retour avec roulottés avariées ou refusées.s) Transport restreint - longue dislance -route restreinte - si De Thetford Mines el Black Lake aux frontières Québec-Nouveau-Brunswick (tous les ports d'entrée) - destination: tous les endroits des provinces maritimes /) Transport restreint - longue distance - route restreinte - D De Thetford Mines el Black Lake aux frontières Québec-Ontario (tous les ports d'entrée) - destination: toutes les provinces à l'ouest dc la province de Ouébec.Restrictions: 1.Dans le cas des clauses s et i.pour le transpon de tentes-roulottes et roulottes origi-nant des usines de Tentes Mobiles Inc.et Apa-laches Industries Ltd.de Thetford Mines, ainsi que des usines de Tentes Confort Inc.de Black Lake, pai lemoiques surbaissées, el retour avec roulottes avariées ou refusées.2.Les clauses 5 et / sont sujettes à la production d'un permis connexe des autorités des provinces concernées.demande à la Commission des transports une modification de son permis afin que lesdiles clauses se lisent à l'avenir comme suit: h) Transport restreint - longue distance \u2022 rayon - h) De Thetford Mines.Black Lake el Sl-Louis-de-Blandford à tous les endroits situés dans la province de Ouébec.pour le transport de lenles-rouloltes el roulottes origirant des usines d'Apalache Industries Ltd.et Tentes Mobiles Inc.de Thetford Mines, des usines de Tentes Confon Inc.de Black Lake, ainsi que des usines dc Valbar Inc.de Sl-Louis-de-Blandford.avec remorques surbaissées et retour avec roulottes avariées ou refusées.1) Transport restreint - longue distance -route restreinte - j) De Thetford Mines.Black Lake et Sl-Louis-de-Blandford aux frontières Québec-Nouveau-Brunswick (tous les ports d'entrée) destination, tous les endroits des provinces mari-limes.I) Transport restreint - longue cistanec - route restreinte - /) Dc Thetford Mines.Black Lake el Sl-Louis-dc-Blandford aux frontières Québec-Ontario (tous les pons d'enliée) destination: unîtes les provinces à l'ouest de Ii province de Ouébec.Restrictions: 1.Dans le cas des clauses s et /.pour le transport de tenles-roulollcs et roulotlcs origi-nani des usines de Tentes Mobiles Inc.et Apa-laches Industries Ltd .dc Thetford Mines, del usines de Tentes Contort Inc.d; Black Lake cl des usines de Valbar Inc.de St-Louis-de-Blandlord.par remorques surbaissées, et retour avec roulottes avarices ou refusées.2.Les clauses 1 el 1 sont sujettes à la production d'un permis connexe des autorités des provinces concernées and trailers originating from Ihe factories of Apalache Industries Ltd.and Tenles Mobiles Inc.in Thetford Mines, and also from the factories of Tentes Confort Inc.in Black Lake, and return with damaged or refused nailers.(j) Restricted trucking - long distance - restricted route - is) From Thetford Mines and Black Lake lo the Ouébec-New Brunswick border tall pons of entry - destination: all points in (he Maritime Provinces.(/) Restricted trucking - long distance - restricted route - (r) From Thetford Mines and Black Lake 10 Ihe Ouebec-Onlario border (all ports of entry) -destination: all the provinces located to the west of the Province of Quebec.Restrictions: 1.In the case of clauses s and /.for the transport, by lowbed trailer, or trailer tents and uaiiers originating trom the factories of Tentes Mobiles Inc.and Apalache Industries Ltd.in Thetford Mines, and also from Ihe factories of Tentes Confon Inc.in Black Lake, and return with damaged or refused trailers.2.Clauses 5 and 1 are subject to the issue of a related permit by the authorities of the provinces concerned.requests from the Transport Commission that its permit be modified so thai said clauses read henceforth as follows: (h) Restricted trucking - long distance - radius - (/i) From Thetford Mines.Black Lake and St-Louis-de-Blanford to all points located in the Province of Québec, for the transport, by low-bed trailer, of trailer tents and trailers originating from the factories of Apalache Industries Ltd.and Tentes Mobiles Inc.in Thetford Mines, from Ihe factories of Tentes Confon Inc.in Black Lake, and also from the factories of Valbar Inc.in St-Louis-de-Blandford.and return with damaged or refused nailers.(j) Restricted trucking - long distance - restricted route - (s) From Thetford Mines.Black Lake and St-Louis-de-Blandford 10 the Quebec-New Brunswick border (all ports of entry 1 destina-lion: all points in the Maritime Provinces.U) Restricted trucking - long distance - restricted route - (/) From Thetford Mines.Black Lake and St-Louis-de- Blandford to the Ouébec-Ontaiio border (all ports of entry) destination: all provinces located to the west of the Province of Ouébec Restriclions: 1.As for clauses s and 1, for the transport, by lowbed trailer, of trailer tents and trailers originating from the factories of Tentes Mobiles Inc.and Apalache Industries Ltd.in Thetford Mines, from Ihe factories of Tenles Confort Inc.in Black Lake and from the factories ol Valbar Inc.in St-Louis-de-Blandford.and return with damaged or refused trailers.2.Clauses \\ and 1 are subject 10 the issue of a related permit from the authorities ol ihe provinces concerned. GAZETTE OIE ICI ELLE DU QUÉBEC, 3 mai 197:,.107' année, n\" 18 3599 Rôle 0-3478 47-DYV-D-l LOCATION Tl-BO ENR.450, Père-Lacombe Ouébec 8 (Oué.) Rôle O-3480 24157-V-D-1 BOUCHARD.NAPOLÉON 274, de l'Anse Roberval (Oué.) Rôle 0-3481 3I2-V-D-2 HAMEL TRANSPORT LOTBINIÈRE LIMITÉE 155, rue Principale Sie-Croix (Lolbinière) (Oué.) cl / and 5IIS-V BÉCANCOUR EXPRESS TRANSPORT INC CP.127 Deschaillons (Oué.) Rôle 0-3482 5II5-V-D-2 BÉCANCOUR EXPRESS TRANSPORT INC.CP.127 Deschaillons (Oué.) el / and 312-V HAMEL TRANSPORT LOTBINIÈRE LIMITÉE 155, rue Principale Sle-Croix (Lolbinière) (Oué.) Rôle O-3502 O-20I497 LALIBERTÉ.EDGAR 692.Sl-François Esl Ouébec (Oué.) O-20I538-D-2 TÉTREAULT, MICHEL 74, Dugas Beauport (Oué.) Rôle O-3503 Q-201560-D-3 BLOUIN.ROLLAND 380.12e Avenue Senneierre (Oué.) O-2001I8-D-2 GAGNON, NORMAND 970.8e Avenue, app.5 Senneierre (Oué.) Changement d'adresse: La partie requérante demande à la Commission des transports du Ouébec l'autorisation de changer son local de location situé au 450.Pcrc-Lacombe.Ouébec 8 pour celui de: 449.rue Blériol Parc Colbert Ste-Foy.Québec 10 (Quel Nouvelle demande: La panie requérante demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation de donner le service de transport suivant: Transpon restreint - service local - contrat -Transport de linge souillé du Centre Psychiatrique de Roberval à l'Hôtel-Dieu de Roberval.et retour avec le lirge propre, pour le compte de l'Hôtel-Dieu de Roberval.Modification dc permis: Transpon par remorquage \u2022 contrai -Demande est faite d'autoriser Hamel Transport Lolbinière Limitée à tirei avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Bécancour Express Transport Inc.permis no 5II5-V.scion toutes les clauses a à C dudit peinus no 5115-V.Change of address: The applicant requests from the Quebec Transport Commission authorization to change the location of its leasing office from 450 Père-Lacombe.Ouebec 8 to: 449 Blériol Street Pare Colbert Ste-Foy.Ouébec 10.P.O.New application: The applicant requests from Ihe Québec Transport Commission authorization to provide the following transport service: Restricted trucking - local service - contract -Transport of soiled linen from the Centre Psychiatrique de Roberval to Ihe Hôlel-Dieu de Roberval.and return with clean linen, on behalf of l'Hôtel-Dieu de Roberval.Modification of permit: Haulaway transportation - contract -Request is made in order lo authorize Hamel Transport Lolbinière Limitée to haul, with its duly-registered tractors, the trailers of Bécancour Express Transport Inc.permit No.5115-V.according to all clauses, from a 10 /, of said permit No.5115-V.Modification de permis: Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Bécancour Express Transport Inc.à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Hamel Transpon Lolbinière Limitée, permis no 312-V selon toutes les clauses a à / dudit permis no 312-V.Modification of permil: Haulaway transportation - contract -Request is made in order lo authorize Bécancour Express Transport Inc.to haul, with its duly-registered tractors.Ihe trailers of Hamel Transport Lotbinière Limitée, permit No.312-V.according to all clauses, from a to /.of said permil No.312-V.Demande de transfert: Laliberté.Edgar, demande à la Commission de transférer à: Tétreault.Michel 74.Dugas Beauport (Que.) le permis no Q-201497 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération A-36.Québec.Demande de transfert: Bloum.Rolland, demande à la Commission de transférer à: Gagnon.Normand 970.8e Avenue, app.5 (Senneterre) (Que.) le permis no Q-20I560-D-3 pour effectuer du Iransport par véhicule-taxi dans la région suivante: la municipalité de Senneterre.Application for transfer: Laliberté.Edgar, requests the Commission to transfer to: Tétreault, Michel 74 Dugas Beauport (Que.) permil No.Q-201497 to effect transport by taxi-cab in Conglomeration A-36.Québec.Application for transfer: Blouin.Rolland, requests Ihe Commission to transfer to: Gagnon.Normand 970-8th Avenue.Apt.5 (Senneterre) (Que.) permit No.O-20I560-D-3 to effeci iransport by taxicab in the following region: the Municipality of Senneterre. 3600 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, NO.18 Rôle Q-3504 21839-V-D-3 BOURQUE, ÉRIC J.BP.96 Maria (Bonavenlure) (Que.) el / and TRANSPORT E.J.BOURQUE LTÉE E.J.BOURQUE TRANSPORT LTD.B.P.96 Maria (Bonavenlure) (Que.) Demande de Iransfert: Eric J.Bourque demande que son permis de iranspon no 21839-V soil transféré à: Transpon E.J.Bourque Liée E.J.Bourque Transport Ltd.BP.96 Maria (Bonavenlure) (Que.) lequel se lit comme suit: a) Transport restreint - longue dislance -route restreinte - contrat - a) Dc Rivière-au-Renard, Gaspé.Newport et Paspébiac à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick (port d'entrée: Cross Point), en transit dans le Nouveau-Brunswick: destination: Boston, Gloucester.Rhode Island.New York.Pennsylvanie el Ohio, pour le transport de poissons frais et congelés (marchandise exempte des règlements de {'Interstate Commerce Commission), pour le compte des Pécheurs Unis de Ouébec.ft) Transport restreint - longue distance \u2022 roule restreinte - b) De tous les endroits silués dans les districts électoraux provinciaux de Bonavenlure et Gaspé-Sud à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick; destination: Boston.Gloucester.Rhode Island, New York, Pennsylvanie el Ohio, pour le transport de fruits de mer, poissons frais et congelés, crustacés, morues et poissons séchés (marchandise exempte des règlements de Y Interstate Commerce Commission), pour le compte de tout expéditeur.Droit additionnel re/ Clauses a el b: En donnant les services autorisés par les clauses o et 6 de son permis, le détenteur est autorise à utiliser des remorques réfrigérées.Restriction re/ Clauses a et b Les services autorisés par les clauses a et ft de ce permis ne seront opérés que conjointement avec le permis no 889, classe PO-X, de la Motor Carrier Board du Nouveau-Brunswick, en date du 26 janvier 1970.c) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - c) De Montréal et tous les endroits silués dans un rayon de trente (30) miles de cet endroit à Maria, comté de Bonaventure.et à tous points silués dans la péninsule gaspésienne, pour le transport de matériaux de constiuction, excluant les matériaux d'isolation et la brique, pour le compte de Cyr & Paradis Inc.de Maria, comté de Bonaventure, el retour.d) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - d) Dc Montréal et tous les endroits situés dans le rayon de trente (30) milles de cet endroit à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick (port d'entrée Pointe-à-la-Croix); destination: Fredé-ricton et Dalhousie, N.B., pour le transport de matériaux de construction excluant les matériaux d'isolation et la brique, pour le compte de Cyr & Paradis Inc., de Maria, comté de Bonavenlure.et retour.Condition re/ Clause d: Ce service devra être opéré conjointement avec un permis complémentaire à être émis par la Motor Carrier Board du Nouveau- Brunswick et dont copie devra être déposés au dossier.Application for transfer: Eric J.Bourque requests that his transport permit No.21839-V be transferred to: Transport E.J.Bourque Ltée EJ.Bourque Transport Ltd.B.P.96 Maria (Bonaventure) (Que.) which reads as follows: (a) Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - (o) From Rivière-au-Renard, Gaspé.New-port and Paspébiac to the Québec-New Brunswick border (port of entry: Cross Point), in transit through New Brunswick: destination: Boston.Gloucester.Rhode Island.New York.Pennsylvania and Ohio, for the transport of fresh and frozen fish (goods exempt from the regulations of Ihe Interstate Commerce Commission), on behalf of Pêcheurs Unis de Quebec.(ft) Restricted trucking - long distance - re-tricied route - (ft) From all points located within the Provincial Electoral Districts of Bonaventure and Gaspé-Sud to the Québec-New Brunswick border; destination: Boston, Gloucester, Rhode Island, New York.Pennsylvania and Ohio, for the transport of sea food, fresh and frozen fish, crustaceous.cod and dry fish, (goods exempt from regulations of ihe Interstate Commerce Commission) on behalf of any shipper.Additional right re/ Clauses a and ft: When giving the services authorized by clauses a and ft of his permil.the holder is authorized to use refrigerated vans.Restriclion re/ Clauses a and ft: The services authorized by clauses a and ft of this permit shall be operated in conjunction with permit No.889, class PO-X.of the Motor Carrier Board of New Brunswick, dated January 26lh.1970.(c) Restricted trucking - long distance - restricted route - contrai - (c) From Montreal and all points located within a radius of thirty (30) miles from said Cily to Maria.County of Bonaventure and to all points located within Gaspé Peninsula, for the transport of construction materials, excluding insulated materials and bricks, on behalf of Cyr & Paradis Inc., Maria, County of Bonaventure.and return.(%, payable semi-annuellement les 15 décembre et 15 juin de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission: cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juin 1975.Tableau d'amortissement \u2014 $1.382.000 \u2014 20 ans \tDate\t\tCapital 15\t06\t1976 .\t.$ 33,000 15\t06\t1977 .\t.36,000 15\t06\t1978 .\t.40,000 15\t06\t1979 .\t.45,000 15\t06\t1980 .\t.51,000 15\t06\t1981.\t.81,000 15\t06\t1982 .\t.90,000 15\t06\t1983 .\t.98,000 15\t(16\t1984 .\t.109.000 15\t06\t1985 .\t.120,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1.Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2.Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3.Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4.Obligations échéant en série I à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $103,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 juin 1995.Cependant, les soumissions ne devront êlre transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.drale Street.Post Office Box 710, Rimouski.County of Rimouski.P.Q.until 8:00 o'clock p.m.on Wednesday.May 21, 1975, for the purchase of a bond issue of $1.382.000 for the City of Rimouski.County of Rimouski.dated June 15.1975 and redeemable serially from June 15, 1976 to June 15.1995 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%.nor more thant 9 '':%, payable semiannually on December 15th and June 15th of each year.The rate of interesi may be the same for the whole issue; however, should more lhan one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from June 15.1975.Redemption table \u2014 S1.382.000 \u2014 20 years Date Capital 15 06 1986 .$ 55.000 15 06 1987 .43.000 15 06 1988 .48,000 15 06 1989 .54,000 15 06 1990 .60,000 15 06 1991.67,000 15 06 1992 .74,000 15 06 1993 .83,000 15 06 1994 .92,000 15 06 1995 .103.000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.I to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15% year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.I to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $103.000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of June 15, 1995.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for ihe bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 3 mai 1975, 107' année, n° 18 3665 Le capiial el les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Les dites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $103,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 juin de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.Le cité de Rimouski s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juin 1975 sans un autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en venu des règlements numéros: 98 \u2014 $63.000 \u2014 renouvellement d'emprunt: 805 \u2014 $7,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 811 \u2014 $12.800 \u2014 renouvellement d'emprunt; 817 \u2014 $77,200 \u2014 renouvellement d'emprunt; 963 \u2014 $35,500 \u2014 voirie; 964 \u2014 $26.000 \u2014 voirie; 972 \u2014 $47.000 \u2014 aqueduc el égouts; 974 \u2014 $65.000 \u2014 aqueduc et égouts; 976 \u2014 $75,000 \u2014 aqueduc, égouts el voirie; 977 \u2014 $ 13,000 \u2014 voirie; 978 \u2014 $95.000 \u2014 aqueduc et égouts: 980 \u2014 $200,000 \u2014 achat de machinerie; 983 \u2014 $370.000 \u2014 services récréatifs el communautaires; 984\u2014 $26,000 \u2014 aqueduc et égouts: 985 \u2014 $40,000 \u2014 construction d'un poste de police et pompiers: 986 \u2014 $73,000 \u2014 aqueduc et égouts: 987 \u2014 $100.000 \u2014 aqueducs et égouts: 988 \u2014 $33,000 \u2014 réfection à l'hôtel de ville: 994 \u2014 $23,500 \u2014 prêt à l'office municipal d'habitation.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8.00 heures du soir, mercredi, le 21 mai 1975, Hôtel de ville, 205.rue dc la Cathédrale, Case postale 710, Rimouski.comté de Rimouski.P.O.Le conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Rimouski (Comté de Rimouski).ce 24 avril 1975.Le greffier.Hubert Dubé.Hôtel de ville.205.rue de la Cathédrale, Case postale 710.Rimouski (Rimouski), Québec.Téléphone: 723-3313, code 418.607I9-o Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $103,000.and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par.on June 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certifified cheque equal to \\ % of the amount of the loan.The City of Rimouski agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after June 15.1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to bylaws numbers: 98 \u2014 $63.000 \u2014 loan renewal: 805 \u2014 $7.000 \u2014 loan renewal; 811 \u2014 SI2.800 \u2014 loan renewal; 817 \u2014 $77,200 \u2014 loan renewal; 963 \u2014 $35.500 \u2014 roads: 964 \u2014 $26.000 \u2014 roads; 972 \u2014 $47.000 \u2014 waterworks and sewers; 974 \u2014 $65.000 \u2014 waterworks and sewers; 976 \u2014 $75.000 \u2014 waterworks.sewers and roads; 977 \u2014 $ 13,000 \u2014 roads; 978 \u2014 $95,000 \u2014 waterworks and sewers; 980 \u2014 $200,000 \u2014 purchase of machinery; 983 \u2014 $370.000 \u2014 recreational and community services; 984 \u2014 $26,000 \u2014 waterworks and sewers; 985 \u2014 $40.000 \u2014 construction of a police and fire station; 986 \u2014 $73.000 \u2014 waterworks ans sewers; 987 \u2014 $ 100.000 \u2014 waterworks and sewers; 988 \u2014 $33.000 \u2014 City Hall repairs: 994 \u2014 $23.500 \u2014 loan to the Municipal Housing Bureau.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be.to be held at 8:00 o'clock p.m.on Wednesday.May 21.1975, at the City Hall, 205 De la Cathédrale Street.Post Office Box 710.Rimouski.County of Rimouski, P.O.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Hubert Dubé, dry Clerk.City Hall.205 De la Cathédrale Street, Post Office Box 710.Rimouski (Rimouski), Québec.Telephone: 723-3313.code 418 60719 Demandes à la Législature Applications to Legislature Ville de Longueuil Avis est par les présentes donné que la ville île Longueuil s'adrosera à l'Assemblée nationale du Québec à sa présente ou prochaine session ou la session suivante afin d'obtenir l'adoption d'un bill amendant sa charte pour les motifs suivants: 1.Autoriser la Ville à disposer d'immeubles acquis avec une restriction; City of Longueuil Public notice is hereby given that the City of longueuil will apply to the Québec National Assembly, ¦ luring its current or next session or the following one, for the passing of a Bill amending its charter, for the following purposes: 1.To permit the City to dispose of immoveables whose titles contain restrictions as to the future use it wishes to make of them: 3666 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1976, Vol.107, No.18 2.Autoriser la Ville à disposer de terrains acquis en surplus pour des fins municipales; 3.Autoriser la Ville à indemniser les membres du Conseil pour leur vacation à son service; 4.Rendre obligatoire la nomination annuelle de vérificateurs à date fixe; 5.Dispenser le greffier de la Ville de la lecture des règlements et autoriser leur adoption lors d'une assemblée ajournée; 6.Autoriser la Ville à limiter le nombre de commerces d'une même catégorie dans une zone donnée; 7.Éliminer le maximum fixé pour le tarif d'honoraires lors de l'émission de permis de construction; 8.Autoriser la Ville à faire faire la rénovation ou la démolition des habitations insalubres, vétustés ou endommagées sans avoir à se pourvoir en justice à cet effet; 9.Autoriser la Ville à requérir son approbation préalable à toute demande de subdivision, à conclure des conventions garantissant l'exécution des travaux municipaux et la rentabilité des projets de construction; 10.Augmenter de 5% à 10% la superficie des terrains subdivisés pour fins de parcs ou de terrains de jeux; 11.Autoriser la Ville à percer des tunnels en profondeur sous toute propriété pour ses services d'aqueduc et d'égout sans avoir à payer l'indemnité; 12.Permettre la gradation des taux d'intérêt sur les arrérages de taxes; 13.Décréter que les frais de nettoyage de terrains sont assimilés à une taxe; 14.Sanctionner le droit de propriété lors d'une expropriation municipale, lorsque seul le montant de l'indemnité est contesté; 15.Permettre à la Ville d'examiner les effets endommagés lors d'une réclamation contre elle; 16.Autoriser la Ville à enchérir pour un montant supérieur aux taxes municipales lors de ventes à l'enchère ; 17.Reconnaître le droit de propriété de la Ville de certains terrains bordant les rives du St-Laurent dans son territoire; 18.Augmenter les montants minimum et maximum des amendes décrétées par les règlements municipaux; 19.Dispenser de l'approbation des propriétaires les emprunts touchant les travaux d'aqueduc, d'égout, de pavage et d'éclairage; 20.Indexer la pension des membres du Conseil; 21.Permettre à la Ville de détenir un permis de vente de boissons alcooliques; Et toute autre matière utile à la bonne administration des affaires de la Ville.Longueuil, 11 avril 1975.Paul Pellerin, 60622-16-4-o Avocat et procureur de la ville.2.To grant power to the City to dispose of the remaining parts of immoveables acquired for municipal purposes; 3.To authorize the City to pay an indemnity to the Council members for their attendances during their offices; 4.To compel the Council to appoint, yearly, at its first general sitting, two auditors; 5.To grant the City's clerk an exemption from reading any municipal By-laws; 6.To restrict in a zone the number of business of the same category; 7.To permit the City to establish its own tariff of fees payable for the issue of building permits; 8.To grant power to the City to order the demolition of any structures or building that may endanger life; 9.To authorize the City to require its approval in advance for all subdivision requests, to enter conventions to guarantee the execution of municipal works and the self-payment of construction projects; 10.To permit the City to raise from 5% to 10% the percentage of land required for parks and playgrounds purposes as a condition of the approval of a subdivision plan; 11.To exempt the City from paying any indemnity for the tunnelling under private properties at a depth of 25 feet or more; 12.To allow the use of graduated interest rates for tax arrears; 13.To declare that costs for the cleaning of lots are assimilated to taxes; 14.To sanction the right of ownership in a municipal expropriation when only the amount of indemnity is contested ; 15.To allow the City to proceed to the examination of damaged goods in the case of claims against the City; 16.To authorize the City to bid at any sale of immoveable in its territory for an amount higher than the taxes; 17.To cede to the City rights of property on certain lots bordering the St.Lawrence River; 18.To raise the fines imposed by Municipal By-laws; 19.To exempt the City from seeking any approval but of the Minister of Municipal Affairs and the Municipal Commission to execute certain public works; 20.To adjust annually the benefits payable to the Council members under their pension plan; 21.To authorize the City to hold a permit to sell alcoholic beverages in any recreation centers and public places.And for any other Municipal purposes.Longueuil, April 11th, 1975.Paul Pellerin, 60622-16-4-o Attorney for the City of Longueuil, GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1975, 107' année, n° 18 3667 Ville de Bécancour Avis public est donné par les présentes, par les procureurs soussignés, que la Corporation municipale de la ville de Bécancour, comté de Nicolet-Yamaska, s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec, au cours de la présente session, pour demander l'adoption du projet de loi suivant: Attendu Qu'il est dans l'intérêt de la ville de Bécancour et qu'il est nécessaire pour la bonne administration de ses affaires que le présent projet de loi soit adopté; À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec décrète ce qui suit: 1.Le conseil peut, par règlement, construire, administrer et entretenir un système de conduits souterrains où doivent être placés: tous les fils de télégraphe, de téléphone, de télévision et d'éclairage électrique; les fils de distribution de force motrice; les câbles et lignes de transmission appartenant à toute personne détenant ou exerçant un droit ou un privilège à la surface, au-dessus ou au-d.ssous des ruelles privées et des rues, voies, places et rue'bs publiques, ces conduits devant être d'une dimension et d'une capacité suffisantes pour répondre anolement aux besoins actuels et, dans la mesure du raiso mabb, aux exigences futures; régler généralement l'usa e de ce système de conduits.2.Les règlements dét r minant l'usage, l'administration et l'entretien de; conduits souterrains entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Régie des services ^publics.3.À mesure que la ville décide de construire ces conduits souterrains dans une partie quelconque de son territoire, tout propriétaire de câbles ou de lignes de transmission vi ;é par le paragraphe 1 doit, sur avis à cet effet, lui f mrnir les renseignements qu'elle lui demande et décl .rer quelle portion de ces conduits il désire réserver.La ville est autorisée à imposer une amende de vingt-cinq dollars pour chaque jour de retard à fournir ces renseignements et à faire cette déclaration, à compter du soixantième jour de la réception de cet avis.4.Il y a appel à la Régie des services publics, à l'instance de la ville ou d'une autre partie intéressée, de tout règlement, de toute décision et de tout acte quelconque de la ville, dans toute affaire se rapportant à ladite entreprise de canalisation.Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les trente jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication, dans un journal français et dans un journal anglais circulant dans la ville, d'un avis annonçant le fait appelable._ L'appel est formé au moyen d'une inscription déposée entre les mains du secrétaire de la Régie des services publics; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.5.Le conseil peut contraindre toute personne possédant, employant ou entretenant des poteaux, des fils ou câbles aériens, ou des lignes de transmission, à Town of Bécancour Public notice is hereby given by the undersigned attorneys that the Municipal Corporation of the Town of Bécancour, County of Nicolet-Yamaska, will petition to the National Assembly of Québec, during the present session, for the passage of the following bill: Whereas it is in the interest of the Town of Bécancour and necessary for the proper administration of its affairs that this bill be passed; Therefore, Her Majesty, with the advice and consent of the National Assembly of Québec, enacts as follows: 1.The Council may, by bylaw, construct, administer and maintain a system of underground conduits in which shall be placed all telegraph, telephone, television and electric light wires, motive power supply wires, cables and transmission lines owned by any person having or exercising any right or privilege on, under or above private lanes and public streets, highways, squares and lanes, such conduits to be of sufficient size and capacity to meet present requirements amply and to provide to a reasonable extent for future needs, and generally regulate the use of such system of conduits.2.The bylaws determining the use, administration and maintenance of such underground conduits shall come into force and have effect upon their approval, with or without amendment, by the Public Service Board.3.As the Town decides to construct underground conduits in any part of its territory, any owner of cables or transmission lines contemplated in subsection 1 must, upon a notice to that effect, supply the Town with the information which it requires of him and declare what part of such conduits he wishes to reserve.The Town is authorized to impose a fine of twenty-five dollars for each day's delay in supplying such information and making such declaration, from the sixtieth day after receipt of such notice.4.An appeal shall lie to the Public Service Board, at the request of the Town or of another interested party, from any bylaw, decision or act of the Town in any matter connected with the said conduit undertaking.Such appeal must be lodged, under pain of nullity, within thirty days after service on the interested party, or publication in a French newspaper and in an English newspaper of the Town, of a notice advertising the matter appealed from.The appeal shall be filed by an inscription deposited with the secretary of the Public Service Board; notice thereof must be served on the interested party or his attorney.5.The Council may compel any person owning, using or maintaining poles, aerial cables or whires, or transmission lines, to remove them and to instal 3668 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.18 les faire disparaître et à installer dans les conduits souterrains des fils conducteurs convenables, de la manière qu'il spécifie.6.Lorsqu'une personne possédant des câbles ou fils aériens dans une rue, ruelle ou place publique refuse de les faire disparaître et d'installer dans les conduits souterrains de la ville des fils conducteurs convenables, la Régie des services publics peut l'y contraindre, sur appel de la ville.7.La ville est autorisée, par règlement approuvé par la Régie des services publics, à imposer et à percevoir un tarif de toute personne utilisant ses conduits souterrains.» La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.Fait et donné à Québec, ce 27e jour de mars 1975.Les procureurs de la ville de Bécancour, Vézina, Sheeiian, Pouliot, L'Écuyer, 60549-15-4-o Moriv.Pelletier & Lambert.Corporation des Enseignants du Québec Avis est par les présentes donné que la « Corporation des Enseignants du Québec » s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec pour obtenir l'adoption d'une Loi aux fins suivantes: 1.Abrogation de la Loi constitutive de la Corporation des Enseignants du Québec (10 Georges VI, chap.87, et ses amendements) ; 2.Le transfert de tous les biens, droits et obligations de la « Corporation des Enseignants du Québec » à la « Centrale de l'Enseignement du Québec », formée en vertu de la Loi des syndicats professionnels (S.R.Q.1964, chap.146 et amendements); 3.Substitution de la « Centrale de l'Enseignement du Québec » à la « Corporation des Enseignants du Québec » dans toutes les lois, règlements, décrets, conventions collectives, ententes et procédures pendantes.Québec, ce 14 avril 1975.Les procureurs de la Corporation, Grondin, LeBel, Morin, Poudrier, 60649-16-4-o Isabel & Gagnon.Succession J.O.St-Pierre Avis est par les présentes donné que les héritiers de la succession de feu J.O.St-Pierre, de son vivant domicilié en la ville de Stanstead Plain, district de St-François, s'adresseront à l'Assemblée nationale du Québec, au cours de la présente session, en vue d'obtenir l'adoption d'une loi modifiant les dispositions du testament de feu J.O.St-Pierre, afin de permettre le partage immédiat de la succession, sous réserve d'une somme capitale suffisante pour garantir le paiement d'une rente annuelle viagère de $4,000 à Dame Thérèse St-Pierre Fournier.Montréal, ce 10 avril 1975.appropriate wires in the underground conduits, in the manner it specifies.6.When a person owning aerial cables or whites in a street, lane or public place refuses to remove them and to instal appropriate wires in the underground conduits of the Town, the Public Service Board may compel him to do so, on an appeal by the Town.7.The Town is authorized by bylaw approved by the Public Service Board to impose and collect a tariff from any person using such underground conduits.\" This act shall come into force on the day of its sanction.Given in Québec, this 27th day of March, 1975.Vézina, Sheehan, Pouliot, L'Écuyer, Morin, Pelletier & Lambert, 60549-15-4 Attorneys for the Town of Bécancour.Corporation des Enseignants du Québec Notice is hereby given that the \"Corporation des Enseignants du Québec\" will apply to the National Assembly of Québec to request the adoption of a Bill for the following purposes: 1.The repeal of the Act incorporating the \"Corporation des Enseignants du Québec\" (10 George VI, Chapter 87 and amendments) ; 2.The transfer of all property, rights and obligations of the \"Corporation des Enseignants du Québec\" to the \"Centrale de l'Enseignement du Québec\", constituted pursuant to the Professional Syndicates Act (R.S.Q.1964, Chapter 146 and amendments); 3.The substitution of the name \"Centrale de l'Enseignement du Québec\" for \"Corporation des Enseignants du Québec\" in all acts, bylaws, orders, collective and other agreements and pending proceedings.Québec, April 14, 1975.Grondin, LeBel, Morin, Poudrier, Isabel & Gagnon, 60649-16-4 Attorneys for the Corporation.Estate of J.O.St-Pierre Notice is hereby given that the heirs to the estate of the late J.O.St-Pierre, in his lifetime domiciled at Stanstead Plain, District of St-François, will apply to the National Assembly of Québec, during its present session, in order to obtain the adoption of an act modifying the dispositions of the will of the late J.O.St-Pierre, so as to permit the immediate partition of the estate, subject to the setting up of a reserve of a capital amount sufficient to guarantee the payment of a lifetime annuity of $4,000 to Thérèse St-Pierre Fournier.Montreal, April 10, 1975.60618-16-4-0 Les procureurs des requérants, Lapointe et David.60618-16-4-o Lapointe et David, Attorneys for the petitioners. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1975, 107' année, n° 18 3669 Ville de Chibougamau Avis publie est par les présentes donné que la ville de Chibougamau s'adressera à l'Assemblée nationale de Québec, à sa présente session ou à une session subséquente d'icelle, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte sur les matières suivantes : 1.Pour décréter que, dorénavant, les dispositions de l'article 2 de la Loi des villes minières (Statuts refondus, 1964, chapitre 194) ne s'appliqueront pas à la ville; 2.Pour décréter l'annexion au territoire actuel de la ville d'un territoire contigu à ses limites, tel territoire formant actuellement partie de la municipalité de la Baie James de manière à étendre de cinquante (50) milles en profondeur les limites actuelles de la ville, distraction faite du territoire de la ville de Chapais; 3.Pour décréter que, sous réserve de l'article 41 de la Loi du développement de la région de la Baie James (chapitre 34 des lois de 1971), les dispositions du paragraphe c de l'article 29 de la Loi des mines (chapitre 34 des lois de 1965, tel qu'amendé) ne s'appliqueront pas au territoire annexé par la ville sauf quant à la partie réservée par résolution du conseil pour le développement de l'agglomération urbaine, et pour toutes autres fins.Québec, ce 16 avril 1975.Le procureur de la ville, 60654-17-4-0 Pierre Cantin.Assurances FIREMAN'S FUND AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY A vis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que « FIREMAN'S FUND AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY », enregistrée sous le numéro 773 a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 2689 qui l'autorise à compter du 1er juillet 1974 à effectuer dans la Province des contrats relatifs aux genres d'assurance suivants: Vie; Accident et Maladie.Le siège social de la compagnie est situé à 3333, rue California, San Francisco, Californie, États-Unis d'Amérique.La compagnie a nommé M.R.Langlois, Suite 925, Édifice Sun Life, Montréal, son procureur dans la Province.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 14 avril 1975.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province.Le surintendant des assurances, 60740-18-2-o Roger-A.Camaraire.Town of Chibougamau Public notice is hereby given that the Town of Chibougamau will apply to the National Assembly of Québec, at its present session or at a future session thereof, for the adoption of an act amending its charter, for the following purposes: 1.To order that, in the future, the provisions of section 2 of the Mining Towns Act (Revised Statutes, 1964, chapter 194) shall no longer apply to the Town; 2.To order the annexation to the present territory of the Town of a territory contiguous to or adjoining its limits, such territory presently forming part of the territory of the James Bay Municipality with the result that the present limits of the Town shall be extended by fifty (50) miles in depth, excepting however the territory of the Town of Chapais; 3.To order that, under reserve of section 41 of the James Bay Region Development Act (chapter 34 of the laws of 1971), the provisions of paragraph c of section 29 of the Mining Act (chapter 34 of the laws of 1965, as amended), shall not apply to the territory annexed by the Town excepting however that part reserved by the resolution of the council for urban development, and for any other purpose.Québec, this 16th day of April, 1975.Pierre Cantin, 60654-17-4-o Solicitor for the Town.Insurance FIREMAN'S FUND AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY Notice of issue of license and certificate of registration Notice is hereby given that \"FIREMAN'S FUND AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY\", registered under number 773, has obtained the license and certificate of registry number 2689, authorizing it, as from the 1st of July 1974 to undertake in the Province contracts of insurance in the following classes: Life; Accident and Sickness.The head office of the company is situated at 3333 California Street, San Francisco, California, United States of America.The company has appointed Mr.R.Langlois, Suite 925, Sun Life Building, Montreal, its attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 14th of April 1975.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger A.Camaraire, 60740-18-2-o Superintendent of Insurance. 3670 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.18 CHRYSLER LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA CHRYSLER COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE DU CANADA Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que « CHRYSLER LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA \u2014 CHRYSLER COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE DU CANADA », enregistrée sous le numéro 772 a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 2688 oui l'autorise à compter du 1er avril 1975 à effectuer dans la Province des contrats relatifs aux genres d'assurance suivants: Vie; Accident et Maladie, limités à l'assurance crédit collective seulement.Le siège social de la compagnie est situé à 797, chemin Don Mills, Don Mills, Ontario.La compagnie a nommé M.Michael Sheehan, 220 est, Grande-Allée, Québec, son procureur dans la Province.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 14 avril 1975.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province, Le surintendant des assurances, 60741-18-2-o Roger-A.Camaraire.CHRYSLER LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA CHRYSLER COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE DU CANADA Notice of issue of license and certificate of registration Notice is hereby given that \"CHRYSLER LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA \u2014 CHRYSLER COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE DU CANADA\", registered under number 772, has obtained the license and certificate of registry number 2688, authorizing it, as from the 1st of April 1975, to undertake in the Province contracts of insurance in the following classes: Life, Accident and Sickness, restricted to Creditors Group insurance only.The head office of the company is situated at 797 Don Mills Road, Don Mills, Ontario.The company has appointed Mr.Michael Sheehan, 220 Grande-Allée East, Québec, its attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 14th of April 1975.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger A.Camaraire, 60741-18-2-0 Superintendent of Insurance.INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS', MANCHESTER UNITY, FRIENDLY SOCIETY, MONTREAL DISTRICT Avis d'annulation du certificat d'enregistrement Attendu que « INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS', MANCHESTER UNITY, FRIENDLY SOCIETY, MONTREAL DISTRICT » a cessé de faire affaires dans la province de Québec; Attendu que « INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS', MANCHESTER UNITY.FRIENDLY SOCIETY, MONTREAL DISTRICT » a produit au Service des assurances une déclaration à l'effet que le 26 mars 1975, elle ne possédait plus aucun actif, ni aucun passif, ayant distribué son surplus à ses membres, après avoir acquitté toutes ses dettes; En conséquence, avis est par les présentes donné que le certificat d'enregistrement de « INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS', MANCHESTER UNITY, FRIENDLY SOCIETY, MONTREAL DISTRICT » est annulé à compter du 26 mars 1975.Donné au bureau du Service des assurances.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 31 mars 1975.Pour le ministre des mstitutions financières, compagnies et coopératives de la Province, Le surintendant des assurances, 60666-17-2-o Roger-A.Camaraire.INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS', MANCHESTER UNITY, FRIENDLY SOCIETY, MONTREAL DISTRICT Notice of cancellation of certificate of registration Whereas \"INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS', MANCHESTER UNITY, FRIENDLY SOCIETY, MONTREAL DISTRICT\" has ceased to do business in the Province of Québec; Whereas \"INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS', MANCHESTER UNITY.FRIENDLY SOCIETY, MONTREAL DISTRICT\" has filed with the Insurance Branch a declaration to the effect that on the 26th of March 1975, it had no assets and no liabilities, having distributed its surplus to its members after having discharged all its debts; Therefore, notice is hereby given that the certificate of registration of \"INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS', MANCHESTER UNITY, FRIENDLY SOCIETY, MONTREAL DISTRICT\" is cancelled as from the 26th of March 1975.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and cooperatives, the 31th of March 1975.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger-A.Camaraire, 60666-17-2-o Superintendent of Insurance. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1975, 107' année, n° 18 3671 Régie de l'assurance-maladie du Québec Québec Health Insurance Board Liste par région de noms et adresses d'affaires des professionnels de la santé, qui entendent exercer leur profession en dehors des cadres du régime en qualité de professionnels désengagés ou de professionnels non participants ou qui ont cessé d'exercer leur activité en cette qualité, ainsi que la date à laquelle prend effet leur désengagement ou leur non-participation ou la cessation de celle-ci, publiée conformément à l'article 7.01 des règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie, adoptés par arrêté en conseil no 27, en date du 6 janvier 1971.Professionnels désengagés Professionals withdrawn Médecins omnipraticiens General practitioners List compiled on a regional basis, of the names and business addresses of professionals who intend practising their profession outside the scope of the Plan as professionals or who have ceased to practise in this capacity, as well as the date on which their withdrawal or non-participation becomes effective or ceases to become effective, published according to section 7.01 of the regulations respecting the Health Insurance Act adopted by order in council No.27 dated January 6, 1971.Date effective du désengagement Effective date of withdrawal Région de Montréal \u2014 Montreal Region Duchesne, Laurent, 75, boul.Dorchester ouest, Bureau 1017, Mtl (Québec) H2Z 1A4 29-01-71 Région de Québec \u2014 Québec Region Mino, Roland, 2965, 1ère Avenue, Québec (Québec) GIL 3P3 30-05-71 Tremblay, Jacques, 590, St-Cyrille ouest, Québec (Québec) GIS 1S5 23-05-71 Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Chamard, John McLean, 1509 Sherbrooke West, Suite 18A, Montréal (Que.) H3G 1L7 16-08-72 Edmison, Ralph Staples, 1414 Drummond, Apt.826, Montreal (Québec) H3G 1W1 12-04-74 Lamb, Roland Thomas, 1414 Drummond, Suite 1121, Montreal (Québec) H3G 1W1 15-06-74 Région de Québec \u2014 Québec Region Bernier, Louis, 1575, chemin St-Louis, Sillery (Québec) GIS 1G4 21-02-75 Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de la non-participation Effective date of the non-participation Médecins spécialistes Medical specialists Région de Montréal \u2014 Montreal Region Almudevar, Manuel, 612 St.John's Road, Suite 114, Pointe-Claire (Québec) H3R 3K3 01-12-70 Aronovitch, Michael, 4119 Sherbrooke Street West, Montreal (Québec) H3Z 1A7 01-12-70 Barker, Charles S., 9 Nelson, Montreal (Québec) H4X 1E9 01-12-70 Black, Donald Kenneth, Case postale 95, Hudson Heights (Québec) JOP 1J0 01-12-70 Bossé, Jean, 6555, boul.Gouin ouest, Montréal (Québec) H4K 1B3 24-09-72 Boulanger, Jean-Baptiste, 3610, avenue Atwater, Montréal (Québec) H3H 1Y6 16-04-71 Brabander, Joachim, 1390 Sherbrooke Street West, Montreal (Québec) H3G 1J9 01-12-70 Brow, George Raymond, 1374 Sherbrooke Street West, Suite 7, Montreal (Que.) H3G 1J6 01-12-70 Browman, Mark, 7841 - 2nd Avenue, Montreal (Québec) H1Z 2S2 30-07-71 Butler, Albert A., Medical Arts Bldg., Montreal (Québec) H3G 1L5 01-12-70 Cantero, Antonio, 1396, Stc-Catherine ouest, Montreal (Québec) H3G 1P9 01-12-70 Copping, Gordon A., 724 Upper Belmont Avenue, Montreal (Québec) H3Y 1K4 01-12-70 Cordeau, Claire, 1392, Jean-Talon est, app.301, Montréal (Québec) H2E 1S4 06-01-73 David, Paul P., 8705, rue Barbeau, Montréal (Québec) H1R 2N3 01-12-70 Dawson, Howard L., 14 Bellevue Avenue, Westmount, Montreal (Québec) H3Y 1G5 01-12-70 3672 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.18 Professionnels non participants Non-participating professionals Dale effective de non-participation Effective date of non-participation Médecins spécialistes Medical specialists Region de Montréal \u2014 Montreal Region Dumais, Gaston, 12245, Grenet, app.112, Montréal (Québec) H4J 2J6 27-03-71 Eakin, W.W., 1538 Sherbrooke Street West, Apt.704, Montreal (Québec) H3G 1L5 15-01-71 Feeney, Neil, 27 Holton Avenue, Westmount, Montreal (Québec) H3Y 2E9 27-04-74 Fullerton, C.W., 1414 Drummond Street, Montreal (Québec) H3G 1W1 01-12-70 Gélinas, André, 565, Javelin, Dorval (Québec) H9P 2C1 01-12-70 Genest, Armand, 30, boul.St-Joseph est, app.818, Montréal (Québec) H2T 1G9 29-01-71 Gibbard, Bruce A., 4324 Sherbrooke West, Suite 48, Montreal (Québec) H3Z 1E1 30-06-74 Gold, Michael M., 5785 Côte des Neiges, Apt.105, Montreal (Québec) H3S 1Y8 01-12-70 Hunt, Brian R., 1538 Sherbrooke West, Apt.622, Montreal (Québec) H3G 1L5 03-01-73 Johnston, Kenneth B., Main Road, Hudson, Vaudreuil (Québec) J0P 1H0 31-12-70 Korenberg, Lela C, 1538 Sherbrooke Street West, Suite 601, Montreal (Québec) H3G 1L5 26-08-72 Korenberg, Morton, Medical Arts Bldg., Montreal (Québec) H3G 1L5 01-12-70 Kravitz, Henry, 4994 Circle Road, Montreal (Québec) H3W 1Z7 10-06-72 Larivière, Paul, 3484, avenue Laval, Montréal (Québec) H2X 3C8 01-12-70 Legendre, J.Henri, 969, boul.St-Joseph est, app.3, Montréal (Québec) H2J 1K9 01-12-70 Levy, Léonard, 3545, Côte des Neiges, app.118, Montréal (Québec) H3H 1V1 06-04-73 MacDonald, Allison D., 3550 Côte des Neiges, Apt.110, Montreal (Québec) H3H 1V4 01-12-70 MacFarlane, Malcolm R., 1538 Sherbrooke St.West, Apt.601, Montreal (Québec) 26-08-72 H3G 1L5 Maguire, J.Gordon, 4485, Sherbrooke ouest, Westmount, Montréal (Québec) H3Z 1E7 13-02-71 Manseau, J.Arthur, 960, boul.St-Joseph est, Montréal (Québec) H2J 1K8 01-12-70 Mason, Edward Halton, 3465, Côte des Neiges, Suite 81, Montréal (Québec) H3H 1T7 07-01-71 Melhado, Gérald Carlton, 900 Sherbrooke St.West, Montreal (Québec) H3A 1G3 01-01-71 Moll, Albert Edward, 3550 Côte des Neiges Road, Suite 570, Montreal (Que.) H3H 1V4 25-04-72 Montgomery, Lome C, 556 Grosvenor Avenue, Montreal (Québec) H3Y 2S4 01-12-70 Morin, Paul, 1280, Girouard, St-Hyacinthe (Québec), J2S 2Z1 01-12-70 Nadler, Norman J., 4141 Sherbrooke O., app.540, Montréal (Québec) H3Z 1B8 01-12-70 Naiman, James, 4330, Sherbrooke ouest, Montréal (Québec) H3Z 1E1 01-03-72 Nerman, Yale, 1115 Sherbrooke West, Suite 1403, Montreal (Québec) H3A 1H3 03-01-71 Pearson, Georges J.R., 5715, avenue Darlington, app.1, Montréal (Québec) H3S 2H6 01-12-70 Robert, Paul, 3489, avenue Atwater, app.6, Montréal (Québec) H3H 1Y2 03-02-71 Scott, W.Clifford M., 1260 McGregor Avenue, App.405, Montreal (Québec) H3G 1B6 01-12-70 Smith, Clifton Conway, 1538 Sherbrooke St.West, Suite 1020, Montreal (Québec) 01-12-70 H3G 1L5 Smith, Frederick Mclver, 631 Roslyn Avenue, Montreal (Québec) H3Y 2V1 01-12-70 Stein, Samuel, 1025 Pine Avenue West, Montreal (Québec) H3A 1A1 01-07-72 Tucker, Elrie Clifford, 1390 Sherbrooke St.West, Apt.2, Montreal (Québec) H3G 1J9 01-12-70 Wood, David John, 4119 Sherbrooke West, Westmount, Montreal (Québec) H3Z 1A7 17-05-74 Région de Québec \u2014 Québec Region Lapointe, Donat, 220, Grande-Allée est, app.650, Québec (Québec) G1R 2J1 13-01-71 Larue, Lucien, 964, Casot, Québec (Québec) GIS 2Y2 26-12-70 Parrot, Paul, 1328, avenue des Pins, Sillery, Québec (Québec) GIS 4J5 01-12-70 Médecins omnipraticiens General practitioners Région de Montréal \u2014 Montreal Region Auger, Paul, 74, rue Principale, Granby, Shefford (Québec) J2G 2T4 Archambault, Paul-A., 2805, Willowdale, Montréal (Québec) H3T 1H6 Barakett, William, 1005, Main, Cowansville (Québec) J2K 1K4 Bazinet, Pauline, 401, Sud, Missisquoi (Québec) J2K 2X6 Beaudry, Constant, 840, Rouleau, St-Hyacinthe (Québec) J2S 1B7 Bédard, Jean-Paul, 401, rue Sud, Cowansville, Missisquoi (Québec) J2K 2X6 08-05-75 01-05-71 08-05-75 08-05-75 08-05-75 08-05-75 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mai 1975, 107' année, n° 18 Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participation Médecins omnipraticiens General practitioners Région de Montréal \u2014 Montreal Region Bhérer, Robert, 1240, rue Versailles, St-Césaire, Rouville (Québec) JOL 1T0 08-05-75 Boisseau, Marc-R., 75, rue St-François, St-Pie, Bagot (Québec) JOH 1W0 08-05-75 Bonin, Roland, 42, rue Paré, Granby, Shefford (Québec) J2G 5C8 08-05-75 Bouvier, Gilles, 645, rue St-Pierre, La Providence, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1R3 08-05-75 Brien, Gilles, 435, rue Mondor, St-Joseph de St-Hyacinthe (Québec) J2S 5A8 08-05-75 Brodeur, Gilles, 2055, rue Girouard, St-Hyacinthe (Québec) J2S 3A7 08-05-75 Brodeur, Y van, 2128, boul.Lafraniboise, St-Hyacinthe (Québec) J2S 4X4 08-05-75 Brouillé, Raynald, 3775, Saint-Hubert, app.10, Montréal (Québec) H2L 3Z9 02-01-71 Brown, Thomas, 1005, Principale, Cowansville (Québec) J2K 1K4 08-05-75 Bruneau, René, 9, rue Dufferin, Granby, Shefford (Québec) J2G 4W5 08-05-75 Brunelle, Simon, 9, rue Dufferin, Granby, Shefford (Québec) J2G 4W5 08-05-75 Campbell, Robert, 2015, Giiouard, St-Hyacinthe (Québec) J2S 4X5 08-05-75 Chaput, Jean-M., 255, Notre-Dame, St-Pie, Bagot (Québec) JOH 1W0 08-05-75 Chartier, Marcel, 2282, rue Ste-Anne, St-Hyacinthe (Québec) J2S 5H6 08-05-75 Chevrefiis, Paul-E., 7960, Saint-Denis, Montréal (Québec) H2R 2G1 13-12-70 Chicoine, Jean-Pierre, 1705, Girouard, St-Hyacinthe (Québec) J2S 3A2 08-05-75 Cholette, Albert M., 5001, Gamier, Montréal (Québec) H2J 3T1 01-01-74 Corbeil, Jules, 435, rue Mondor, St-Hyacinthe (Québec) J2S 5A8 08-05-75 Côté, Sarto-S., 177, rue Empire, Granby, Shefford (Québec) J2G 3B3 08-05-75 Daigle, Jean-M., 401, rue Sud, Cowansville, Missisquoi (Québec) J2K 2X6 08-05-75 Daudelin, André, 645, St-Pierre, La Providence, St-Hyacinthe (Québec) J2T 2R3 08-05-75 Desautels, Rosaire, 990, DesMeules, Douville, St-Hyacinthe (Québec) J2S 6Z3 08-05-75 Desmeules, Jean, 401, rue Sud, Cowansville, Missisquoi iQuébec) J2K 2X6 08-05-75 Dubé, Roch, 135, St-Antoine nord, Granby, Shefford (Québec) J2G 5G7 08-05-75 Dupont, Gérald, 1230, Notre-Dame, St-Césaire, Rouville (Québec) JOL 1T0 08-05-75 Dupont, Richard, 135, St-Antoine nord, Granby, Shefford (Québec) J2G 5G7 08-05-75 Fontaine, André, 1800, Desaulles, St-Hyacinthe (Québec) J2S 2T2 08-05-75 Gordon, Lionel, 6235A Lennox Avenue, Montreal (Québec) H3S 2N6 15-01-72 Gosselin, Alexandre, 192, Principale, St-Damase, St-Hyacinthe (Québec) JOH 1J0 08-05-75 Gosselin, Richard, 78, rue Court, Granby, Shefford (Québec) J2G 4Y5 08-05-75 Guertin, Jean, 98, rue Laval, Granby, Shefford (Québec) J2G 7G8 08-05-75 Hevey, Georges, 795, me Ste-Anne, St-Hyacinthe (Québec) J2S 5G6 08-05-75 Jacques, Elphège, 190, rue Principale est, Farnham (Québec) J2N 1L4 01-12-70 Joannette, Jean-Paul, 4930, Mayfair, Montréal (Québec) H4V 2E7 01-12-70 Labranche, Dorian, 15, rue Gill, Granby, Shefford (Québec) J2G 5C5 08-05-75 Lague, Normand, Case postale 550, Sutton, Brome (Québec) G0E 2K0 08-05-75 Lague, Paul, Ste-Madeleine, St-Hyacinthe (Québec) JOH ISO 08-05-75 Lessard, André, 2780, rue Raymond, St-Hyacinthe (Québec) J2S 5W7 08-05-75 L'Heureux, Jacques, 135, St-Antoine nord, Granby, Shefford (Québec) J2G 5G7 08-05-75 Marcoux, Laurent, 354, Rg Bord de l'Eau est, St-Denis sur Richelieu (Québec) JOH 1K0 08-05-75 Mayette, Richard, 78, rue Court, Granby, Shefford (Québec) J2G 4Y5 08-05-75 Mayman, Abe, 5845 Côte des Neiges, Suite 690, Montreal (Québec) H3S 1Z4 17-12-70 Ménard, Réjean, 78, rue Court, Granby (Québec) J2G 4Y5 08-05-75 Millette, Pierre, 109, St-François, St-Pie, Bagot (Québec) JOH 1W0 08-05-75 Monast, N.E-, 107, rue Davignon, Cowansville, Misissiquoi (Québec) J2K 1N7 08-05-75 Noiseux, Maurice, 9, rue Dufferin, Granby, Shefford (Québec) .I2G 4W5 08-05-75 Norton, Robert, 406, rue Sud, Cowansville (Québec) J2K 2X7 08-05-75 Ouellette, André, 406A, rue Sud, Cowansville (Québec) J2K 2X7 08-05-75 Paquin, Claude, 406A, rue Sud, Cowansville (Québec) J2K 2X7 08-05-75 Pavilanis, Alain V., 1005, Main, Cowansville (Québec) J2K 1K4 08-05-75 Pearl, Hvman, 35, St-Joseph, Granby, Shefford (Québec) J2G 6T5 08-05-75 Pelletier, Gérard, 35A, Notre-Dame, St-Hugues, Bagot (Québec) JOH 1N0 08-05-75 Pincott, Robert S., 1005, Main, Cowansville (Québec) J2K 1K4 08-05-75 Quenneville, Emile, 135, St-Antoine nord, Granby, Shefford (Québec) J2G 5G7 08-05-75 3674 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.18 Professionnels non participants Non-participating professionals Médecins omnipraticiens General practitioners Région de Montreal \u2014 Montreal Region Richard, Jean-Paul, 855, rue St-Louis, St-Hyacinthe (Québec) J2T 3E9 Rodrigue, Marcel, 389, boul.Leclerc, Granby, Shefford (Québec) J2G 1V7 Roy, François, 78, rue Court, Granby, Sh( fford (Québec) J2G 4Y5 Roy, P.E., 150, Montée Lebeau, Cowansville, Mississiquoi (Québec) St-Pierre, Guy, 690, de la Concorde, St-Hyacinthe (Québec) J2S 4P4 Scott, Benjamin H., 5146 Westbury Avenue, Montreal (Québec) H3W 2W3 Tector, David J.G., 1005 Main Street, Cowansville (Québec) J2K 1K4 Viens, Gilles, 1705, Girouard, St-Hyacinthe (Québec) J2S 3A2 Vincent, Gilles, 2780, rue Raymond, St-Hyacinthe (Québec) J2S 5W7 Vines, Norman M., 1452 Bishop Street, Apt.3, Montreal (Québec) H3G 2E7 Dale effective de non-participation Effective date of non-participation 08-05-75 08-05-75 08-05-75 08-05-75 08-05-75 22-07-71 08-05-75 08-05-75 08-05-75 01-12-70 Région Saguenay - Lac-St-Jean \u2014 Saguenay - Lac-St-Jean Region Aubé, Raymond, 665, rue de la Gare, Alma (Québec) 23-05-75 Beaudet, Pierre, 44, rue Rhainds, Chicoutimi-Nord (Québec) 23-05-75 Beaulieu, Léon, 10, rue Petit, St-Honoré (Québec) 23-05-75 Bédard, André, 973, rue Paradis, Roberval (Québec) 23-05-75 Bédard, Robert, 1230, boul.Walberg, app.10, Dolbeau (Québec) G0W 3A0 23-05-75 Bergeron, André, 1412, Roussel, Chicoutimi-Nord (Québec) 23-05-75 Bilodeau, Serge, 168, rue Morin, Jonquière (Québec) 23-05-75 Blouin, Jean.1230, boul.Walberg, app.10, Dolbeau (Québec) G0W 3A0 23-05-75 Blouin, Denis, 1230, boul.Walberg.app.10, Dolbeau (Québec) G0W 3A0 23-05-75 Boily, Laval, 1019, rue Bellevue, St-Félicien (Québec) 23-05-75 Boivin, Jean, 501, boul.du Centenaire, Jonquière (Québec) 23-05-75 Bouchard, Gaston, 291, St-Dominique, Jonquière (Québec) 23-05-75 Boucher, Daniel, 169, rue St-Denis, Arvida (Québec) 23-05-75 Boucher, Marcel F., 110, rue St-Alphonse, St-Bruno, Lac St-Jean (Québec) 23-05-75 Brassard, Benoit, 1056, boul.St-Joseph, Roberval (Québec) 23-05-75 Brassard, J.-Émile, 129, St-Domi nique, Jonquière (Québec) 23\u201405-75 Castonguay, André, 1230, boul.Walberg, app.10, Dolbeau (Québec) G0W 3A0 23-05-75 Champoux, Serge, 107, rue Mathias, app.12, Arvida (Québec) 23-05-75 Claveau, Cléophas, 681, rue Bagot, Bagotville (Québec) 23-05-75 Claveau, Robert, 282, rue St-Vallier, Chicoutimi (Québec) 23-05-75 Couture, André, 297, rue Ste-Geneviève, Chicoutimi-Nord (Québec) 25-05-75 Crête, Yves, 737, rue Aima, app 43, Chicoutimi (Québec) 23-05-75 Dallaire, Réal, Case postale 100, Albanel, Roberval (Québec) 23-05-75 D'Entremont, Félicien, 18, Route 170, Anse St-Jean (Québec) 23-05-75 Drolet, Daniel, 44, Rhainds, Chicoutimi-Nord (Québec) 23-05-75 Drolet, Rénald, 226, Dequen, Aima (Québec) 23-05-75 Dumas, Wilfrid, 1075, boul.Sacré-Coeur, St-Félicien (Québec) 23-05-75 Fleury, André, 255, Collard, Aima (Québec) 23-05-75 Fluet, Bruno, 665, de la Gare, Aima (Québec) 23-05-75 Fortier, Gérald, 304A, St-Hubert, Jonquière (Québec) 23-05-75 Gagné, Carol, Centre Médical St-Félicien, Case postale 576, 1075, boul.Sacré-Coeur, 23-05-75 St-Félicien (Québec) Gagné, Michel, 44, Rhainds, Chicoutimi-Nord (Québec) 23-05-75 Gagnon, Armand, 455, Elgin, Bagotville (Québec) 23-05-75 Gagnon, Roger, 177, St-Jean-Baptiste, Arvida (Québec) 23-05-75 Gaudreault, Mauri), 461.Vilmond, Chicoutimi (Québec) 23-05-75 Gauthier, Isidore, Case postale 10, Dclisle, Lac St-Jean (Québec) 23-05-75 Gauthier, Rémi, 482, 4e Rue, Case postale 126, Port-Alfred (Québec) 23-05-75 Gervais, Gérard, 665, de la Gare ouest, Aima (Québec) 23-05-75 Girard, Jean-Marie, Case postale 129, St-Nazaire, Lapointe (Québec) 23-05-75 Giroux, Marc, 479, St-Jude sud.Aima (Québec) 23-05-75 Gobeil, Louis-Joseph, 3091, boul.Grande-Baie, Port-Alfred (Québec) 23-05-75 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 mai 1976.107' année.«» 18 3675 Professionnels non participants Non-participating professionnels Date effective de non-participation Effective date of non-participation Médecins omnipraticiens General practitioners Région Saguenay - Lac St-Jean \u2014 Saguenay - Lac St-Jean Region Godbois, Jacques, 37, Rhainds, Chicoutimi-Nord (Québec) Guay, Serge, 291, St-Dominique, Jonquière (Québec) Guimond, Jean-Victor, Case postale 81, rue des Arcades, Chicoutimi (Québec) Hinse, Michel, 1230, boul.Walberg, app.10, Dolbeau (Québec) Kiss, Erno, 270, Morrison, Arvida (Québec) Lachance, Jean-Claude, 1388, Mgr-Racine, Chicoutimi (Québec) Lachance, Valère, 56, St-André, Métabetchouan (Québec) Lajoie, Pierre, 302, Mellon, Arvida (Québec) Lalancette, Benoit, 473, rue Massenet, app.14, Chicoutimi (Québec) Laliberté, Louis-Alphonse, 160, Ste-Famille, Kénogami (Québec) Lalonde, Richard, 425, Massenet, Coucoutimi (Québec) Larouche, Dollard, 158, rue Price ouest, Chicoutimi (Québec) Larouche, Léon, 850, boul.St-Joseph, Roberval (Québec) Lavoie, Marcel, 230, rue Labrosse, Arvida (Québec) Lefaivre, Robert, 371, 9e Rue.Port-Alfred (Québec) Létourneau, Paul, 512, de l'École, Arvida (Québec) Levesque, L.-M., 520, Montcalm, Chicoutimi (Québec) Levesque, Michel, 665, de la Gare, Aima (Québec) G8B 4L4 Mailloux, Georges, 123, Côté, Bagotville (Québec) Nadeau, Denis, 633, rue Dequen, Chicoutimi (Québec) Ouellet, André, 850, boul.St-Joseph, Roberval (Québec) Pageau, Yves, 850, St-Joseph, Roberval (Québec) Parent, Bernard, 575, rue Morin, Chicoutimi (Québec) Pedneault, Gilles, 1116, Mozart, Chicoutimi (Québec) Plourde, André, 99, rue St-André, St-Jérôme (Québec) Potvin, Léonce, 60, rue Villeneuve, Notre-Dame-d'Héberville, (Québec) Rochette, Denis, 44, Rhainds, Chicoutimi-Nord (Québec) Savard, François, 716, Aima, app.101, Chicoutimi (Québec) Savard, Lucien, 309, Montcalm, Chicoutimi (Québec) Simard, Jean-Marc.948, rue Harvey, Roberval (Québec) Simard.Réal, 405, St-Cyrille, Normandin, Roberval (Québec) Talbot, Denis, 44, rue Rhainds, Chicoutimi-Nord (Québec) Tanguay, Léo, 299, rue Victoria, Case postale 1068, Bagotville (Québec) Thibault, Jean.Case postale 244.180, rue St-Denis, Arvida (Québec) Tremblay, Camille, St-Gédéon, Lac St-Jean (Québec) Tremblay, Jean-Claude, 221, rue Notre-Dame est, Aima (Québec) Tremblay, Paul-Benoit, 660, rue Jacques-Cartier, Chicoutimi (Québec) Vandal, Léo, 158, Price ouest, Chicoutimi (Québec) Villeneuve, Georges-H., 745, Roussel, Aima (Québec) Région de Trois-Rivières \u2014 Trois-Rivières Region Marcotte, Gaston, Case postale 457, Cap-de-la-Madeleine (Québec) G8T 7W6 Région de Québec \u2014 Québec Region Leclaire, Yves, 2832, Valcourt, Québec (Québec) G1W 1W3 Rinfret, Charles G., 1035, boul.Pie XII, Beauport (Québec) G1W 4N6 Samson, J.W., 14, Parc Samuel Holland, app.1607, Québec (Québec) GIS 4M6 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23M)5-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 23-05-75 21-10-71 01-12-70 13-12-70 27-07-72 Région des Cantons de l'Est \u2014 Eastern Townships Region Grainger, Thomas R., CP.1500, John Manville Clinic, Asbestos, Richmond (Que.) JIT 3N2 01-12-70 3676 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1976, Vol.107, No.18 Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participation Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Asselin, Charles, 3410, avenue Benny, app.2A, Montréal (Québec) H4B 2R8 17-08-74 Asselin, Raymond, 45, rue Saint-Georges, St-Jean (Québec) J3B 2S2 17-08-74 Baril, Claude, 3703, rue Dupuis, Montréal (Québec) H3T 1E5 17-08-74 Beaulieu, J.Edouard, Case postale 148, Saint-Rémy, Napierville (Québec) JOL 2L0 30-03-71 Beaumier, Antoine, 489, Victoria, app.440, St-Lambert (Québec) J4P 2J3 26-09-74 Beauséjour, Guv, 3766 Queen Mary Road, Montreal (Québec) H3V 1A6 17-08-74 Bertrand, Jean-Louis, 435, rue Oakville, Dorval (Québec) H9S 2R7 17-08-74 Bieniecki, Irena, 531 Rockland Avenue, Montreal (Québec) H2V 2Z4 02-09-72 Bisaillon, Jean-Jacques, 3333 Queen Mary, app.450, Montréal (Québec) H3V 1A2 17-08-74 Bock, Jean-Guy, 3895, Dandurand, Montréal (Québec) H1X 1P5 31-10-74 Bossé, Lucien, 345, avenue Dorval, app.2, Dorval (Québec) H9S 3H6 17-08-74 Bourcier, René, 5450, Côte des Neiges, app.600, Montréal (Québec) H3T 1Y6 17-08-74 Bourgoin, Jean-Charles, 1248, rue Lajoie, Montréal (Québec) H2P lPl 05-04-71 Bourke, Edward T., 18 Thornhill Avenue, Westmount, Montréal (Québec) H3Y 2E2 09-03-71 Boyles, Williams Howard, 1414 Drummond St., Apt.422, Montreal (Québec) H3G 1W1 02-03-71 Burns, Frank Léonard, 1414 Drummond Street, Apt.1022, Montreal (Québec) H3G 1W1 13-02-71 Bushell, Winston C, 1538 Sherbrooke St.W., Apt.1006, Montreal (Québec) H3G 1L5 10-02-71 Caplan, Herbert, 3535 Queen Mary Road, Apt.315, Montreal (Québec) H3V 1H8 11-01-73 Casaubon, Jacques, 2100, Jean-Talon est, Montréal (Québec) H2E 1V3 30-06-74 Chicoine, Claude R., 1553, rue Viel, Montréal (Québec) H3M 1G6 17-08-74 Coen, Irving, 43 Donegani Avenue, Apt.2, Pointe-Claire [Québec) H9R 2V8 21-06-74 Cohen, Robert H., 5153 Coolbrook Avenue, Montreal (Québec) H3X 2L2 17-08-74 Colle, Albert Joseph, 5253, boul.Décarie, app.218, Montréal (Québec) H3W 3C3 03-02-71 Copelovitch, Bernard, 5845 Côte des Neiges, app.485, Montréal (Québec) H3S 1Z4 17-08-74 Couture, Jean-Paul, 55, avenue de l'Église, app.36, Verdun (Québec) H4G 3E7 17-08-74 Decary, Rémi, 245, Bord du Lac, Dorval (Québec) H9S 2A3 08-02-75 Degrandmont, Claude, 4934, rue Adam, Montréal (Québec) HIV 1W3 08-04-72 De Grandmont, Madeleine, 5870, rue Sherbrooke est, Montréal (Québec) H1N 1B5 17-08-74 De La Fuente, Lucio N., 1000A, Jean-Talon ouest, Montréal (Québec) H3N 1T1 30-05-74 Deom, Guy, 915, avenue Suzanne, Saint-Vincent-de-Paul, Laval (Québec) H7C 2J1 21-02-75 Deom, Marguerite, 915, avenue Suzanne, St-Vincent-de-Paul, Laval (Québec) H7C 2J1 21-02-75 Diner, Murray H., 5757 Decelles, Apt.336, Montreal (Québec) H3S 2C3 26-04-74 Dufresne, Roger, 3333 Queen Mary Road, Apt.440, Montreal (Québec) H3V 1A2 17-08-74 Dundass, Georges M., 4545, Sherbrooke ouest, Montréal (Québec) H3Z 1E8 03-03-73 Elo, James Thomas, 1414 Drummond Street, Apt.909, Montreal (Québec) H3G 1W1 16-02-71 Faith, Robert W., 1538 Sherbrooke Street West, Suite 605, Montreal (Québec) H3G 1L5 17-08-74 Flam, David J\u201e 4495 Sherbrooke Street West, Montreal (Québec) H3Z 1E7 17-08-74 Fortin, Jean-Marc, 2025, boul.Concorde, Laval (Québec) H7G 2G3 17-08-74 Franklin, Gérald, 4078 Gage Road, Montreal (Québec) H3Y 1R5 19-11-72 Gagnon, Pierre, 415, boul.St-Joseph est, Montréal (Québec) H2J 1J6 17-08-74 Gendron, Roland, 900, Sherbrooke ouest, app.12, Montréal (Québec) H3A 1G3 07-03-73 Geoffrion, Paul, 1538, rue Sherbrooke ouest, app.604, Montréal (Québec) H3G 1L5 17-08-74 Geoffrion, Roland, 48, Lakeshore, Pointe-Claire (Québec) H9S 4H4 20-06-74 Griffiths, Victor Bryan, 6600 Trans Canada Hwy., Suite 802, Pte-Claire (Que.) H9R 4S2 17-08-74 Haie, George K., 465 Victoria Avenue, Apt.131, St-Lambert (Québec) J4P 2J2 29-06-74 Harvey, Robert F., 474 Strathcona Avenue, Montreal (Québec) H3Y 2X1 15-04-71 Henry, Donald Ward, 227 Kenaston Avenue, Montreal (Québec) H3R 1M3 31-01-71 Huot, Jean, 3, rue Canal nord, Case postale 268, Greenville (Québec) J0V 1J0 14-02-75 Jones, Ronald G., 3550 Côte des Neiges, app.320, Montréal (Québec) H3H 1V4 31-08-74 Kennedy, Ducan J., 6717 Trans Canada Highway, Pointe-Claire (Québec) H9R 1C4 17-08-74 Kent, Léonard E., 4695 Sherbrooke Street West, Montreal (Québec) H3Z 1G2 07-04-71 Kimura, Akira, 1538 Sherbrooke West, Apt.907, Montreal (Québec) H3G 1L5 31-05-74 Kleinman, Ezra, 4375 Notre-Dame Blvd., Laval (Québec) H7W 1T4 17-08-74 Kutzman, Ernest-Abraham, 1538 Sherbrooke St.W., Apt.410, Montreal (Que.) H3G 1L5 01-02-71 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1976, 107' année, n° 18 3677 Professionnels non participants Non-participâting professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participation Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Labelle, Hubert, 666, Sherbrooke ouest, app.501, Montréal (Québec) H3A 1E7 10-07-74 Labelle, Paul, 11271, Henri-d'Arles, Montréal (Québec) H4K 1T4 ' 11-08-71 Lafleur, Roland, 250, avenue Willibrord, Verdun (Québec) H4G 2T6 06-06-74 Lafortune, Jean-Paul, 5704, Laurendeau, Montréal (Québec) H4E 3W4 13-02-71 Lajoie, J.Gaston, 5305 Queen Mary Road, Montreal (Québec) H3X 1T9 27-07-74 Lalanne, Jean-Guy, 719, 1ère Rue, Iberville (Québec) J2X 3C2 17-01-73 Lamarche, Roger, 6119, Monkland, Montréal (Québec) H4A 1H5 13-01-74 Laporte, J.Octave Lucien, 8655, Foucher, app.405, Montréal (Québec) H2P 2C4 08-01-75 Larue, Charles Arthur, 6746, St-Denis, Montréal (Québec) H2S 2S2 21-06-74 Lawlor, Robert, 3333, chemin Reine-Marie, Montréal (Québec) H3V 1A2 18-02-71 Lefebvre, Pierre L, 2225, boul.Lapinière, Ville Brossard (Québec) J4W 1M3 02-02-71 Lefort, Guy, 42, Principale est, Ste-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1J6 20-06-74 Le François, Guy, 2150, Crescent, Montréal (Québec) H3G 2B8 04-01-75 Legault, J.Victor, 5757, Decelles, app.336, Montréal (Québec) H3S 2C3 01-12-73 Lépine, Louis, 3703, rue Dupuis, Montréal (Québec) H3T 1E5 17-08-74 Lerner, Earl, 23 Valois Bay Avenue, Pointe-Claire (Québec) H9R 4B4 17-08-74 Levitt, Harvey Lawrence, 5757 Decelles Avenue, Apt.3, Montreal (Québec) H3S 2C3 17-08-74 Lussier, Raoul-Eugène, 55, de l'Église, app.36, Verdun (Québec) H4G 3E7 19-09-74 Marchand, Paul-R., 1006, Medical Arts Buildings, Montréal (Québec) H3G 1L5 03-05-74 Mathieu, Leopold, 1103, boul.St-Joseph est, Montréal (Québec) H2J 1L3 15-06-74 Miller, Seymour S., 5025 Sherbrooke St.West, Apt.230 Montreal (Québec) H4A 1S9 17-08-74 Miller, Stephen, 6600 Trans Canada Hwy., Apt.803, Pointe-Claire (Québec) H9R 4S2 17-08-74 Munro, David John, 3550 Côte des Neiges, Apt.400, Montreal (Québec) H3H 1V4 07-12-73 Muroff, Frederick, 1414 Drummond Street, Apt.1104, Montreal (Québec) H3G 1W1 10-03-71 Myles, Thomas A., 1538 Sherbrooke St.West, Suite 412, Montreal (Québec) H3G 1L5 01-02-71 Nadeau, J.-Roland, 3550, Côte des Neiges, app.350, Montréal (Québec) H3H 1V4 17-08-74 Oliver, Austen W., 1414 Drummond Street, Apt.522, Montreal (Québec) H3G 1W1 17-08-74 Parent, Benoît, Place Victoria, app.808, Montréal (Québec) 23-08-72 Pearson, Hyman H., 4780 Côte des Neiges Road, Apt.19, Montreal (Québec) H3V 1G2 06-02-71 Pelletier, Georges, 2150, Crescent, Montréal (Québec) H3G 2B8 10-02-75 Poch, Lewis Neville, 1, Westmount Square, Apt.346, Westmount, Montréal (Québec) 14-04-71 H3Z 2P9 Prosterman, Léonard, 6000 Côte des Neiges Road, Apt.230, Montréal (Québec) H3S 1Z8 17-08-74 Reich, Eric B., 7005 Kildare Road.Apt.4, Montreal (Québec) H4W ICI 17-08-74 Remise, Claude, Faculté de chirurgie dentaire, Case postale 6128, Montréal (Québec) 17-08-74 H3C 3J7 Rennert, Michael D., 5165 Queen Mary Road, Apt.511, Montreal (Québec) H3W 1X7 17-08-74 Robinson, Wilfrid R., 3410, Benny, app.1, Montréal (Québec) H4B 2R8 17-01-74 Rogers, Mervyn Allen, 4300, boul.de Maisonneuve ouest, appt.702, Montréal (Québec) 00-02-71 H3Z 1K8 Rosen, Harry, 3545, Côte Ste-Catherine, Apt.107, Montréal (Québec) H3T 1C7 03-02-74 Saint-Denis, Ronald, 2819, rue Masson, Montréal (Québec) H1Y 1W8 20-06-74 Samis, Philip L., 1, Place Ville-Marie, App.1521, Montréal (Québec) H3B 2B5 17-01-74 Shamv, Frank E., 1414 Drummond, Street, Apt.806, Montreal (Québec) H3G 1W1 17-08-74 Shevell, Melvyn, 6000 Côte des Neiges, Apt.200, Montreal (Québec) H3S 1Z8 13-04-74 Smaill, Stanton S., 1414, Drummond, Suite 1124, Montréal (Québec) H3G 1W1 26-05-74 Solomon, Charles Melvyn, 5165 Queen Mary Road, Apt.506, Montreal (Québec) 17-08-74 H3W 1X7 Stockwell, William Gordon, 1538 Sherbrooke Street West, Suite 805, Montreal (Québec) 09-03-71 H3G 1L5 Swiston, Walter, 4695 Sherbrooke Street West, Montreal (Québec) H3Z 1G2 17-08-74 Sykora, Oskar Paul, Dental Clinic, 1660 Cedar Avenue, Montreal (Québec) H3G 1A3 31-01-71 Vachon, Claude, 1464, rue Crescent, Montréal (Québec) H3G 2B6 17-08-74 Van Vliet, Jonathan E., 1538 Sherbrooke St.West, Apt.805, Montreal (Quebec) 08-03-71 H3G 1L5 3678 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.18 Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participation Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Vinet, Éphrem, 200, Desnoyers, app.815A, Pont-Viau (Québec) H7G 1A6 08-02-71 Vinet, Luc, 500, boul.St-Joseph est, Montréal (Québec) H2J 1J9 03-05-74 Wainberg, Allen, 5845 Côte des Neiges, Apt.300, Montréal (Québec) H3S 1Z4 15-02-75 Walford, Wallace Francis, 1414 Drummond Street, Montreal (Québec) H3G 1W1 30-05-74 Ward, Daryl B., 1414 Drummond Street, Apt.517, Montreal (Québec) H3G 1W1 08-06-74 Wechsler, Morris, 5800 Cavendish Blvd., Apt.510, Côte-St-Luc, Montréal (Québec) 17-08-74 H4W 2T5 Région de Québec \u2014 Québec Region Boucher, Marc, 1000, chemin Ste-Foy, app.302, Québec (Québec) GIS 2L6 31-01-71 Crutchfield, Charles Bruce, 990, des Erables, app.1, Québec (Québec) G1R 2M7 13-06-74 Dion, Majella, 1575, chemin St-Louis, Sillery (Québec) GIS 1G4 17-08-74 Massicotte, Gérard, 1575, chemin St-Louis, Sillery (Québec) GIS 1G4 17-08-74 McGibbon, D.P., 990, des Erables, app.2, Québec (Québec) G1R 2M7 09-06-74 Simard, Armando, 1179, des Erables, Québec (Québec) GlR 2N2 26-05-74 Veillette, Denis, 2860, Quatre-Bourgeois, Ste-Foy (Québec) G1V 1Y3 20-06-74 Région des Cantons de l'Est \u2014 Eastern Townships Region Bellevi le, Paul, 510, Galt ouest, Sherbrooke (Québec) J1H 1Y7 31-05-74 Dugal, Paul-Lau ent, 459A, Lindsay, Drummondville (Québec) J2B 1G9 08-02-71 Gendron, Georges, 189, Notre-Dame sud, Thetford Mines (Québec) G6G 1J5 06-06-74 Gosselin, Viateur, 854, Belvédère sud, Sherbrooke (Québec! JlH 4C1 16-05-73 Lemay, Jules-E., 1855, boul.Portland, Sherbrooke (Québec) J1.I 3V7 17-08-74 Lessard, Pierre, 189, Notre-Dame sud, Thetford Mines (Québec) G6G 1J5 30-05-74 Olivier, Valmore-H., 843, Belvédère sud, Sherbrooke (Québec) JlH 4B9 07-02-71 Région de l'Outoouais \u2014 Oulaouais Region Côté, Roger, 153, Principale, Hull (Québec) J8X 2K4 07-02-75 Proulx, Jacques, 214, boul.Saint-Joseph, Hull (Québec) J8Y 3X4 05-05-71 Région de Témiscamingue \u2014 Témiscamingue Region Bellehumeur, Claude, 10, McQuaig est, Rouyn (Québec) J9X 3B4 11\u201404-74 Région du Saint-Maurice \u2014 St.Maurice Region Dontigny, Vincent, 1350, rue Royale, app.803, Trois-Rivières (Québec) G9A 4J4 17-08-74 Prud'homme, Pierre-P., 1930, 5e Avenue, Shawinigan-Sud (Québec) G9P 1N4 05-05-74 Région du Saguenay \u2014 Saguenay Region Bergeron, Yvon, 72, rue Jacques-Cartier ouest, Chicoutimi (Québec) G7J 1G2 17-08-74 Pharmaciens Pharmacists Région de Montréal \u2014 Montreal Region Jacques, Paul-Léon, 188 est, rue Principale, Farnham, Missisquoi (Québec) 15-09-72 Moisan, Maurice, 3477, Drummond, app.503, Montréal 107 (Québec) 05-01-73 Podlog, Charles, 531, Abercorn, Ville Mont-Royal, Montréal 305 (Québec) 15-03-73 Venne, Rosario, St-Hippolyte, Terrebonne (Québec) 04-04-73 Levasseur, Marcel, 18, Montée-Masson, app.7, St-Vincent-de-Paul, Laval (Québec) 13-12-74 Levy, Mortimer, 67, Holtham Road, Montreal 254 (Québec) 09-02-75 Région du Québec \u2014 Québec Region Laliberté, Jean, Fortierville, Lotbinière, (Québec) 26-10-72 Thibault, Urbain, 9926, Royale, Ste-Anne-de-Beaupré, Québec 22-09-72 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1975, 107' année.n° 18 3679 Professionnels non participants San partir)paling professionnels Date effective de non-participation Effective date of non-participation Pharmaciens Pharmacists Région du Saguenay \u2014 Lac-St-Jean \u2014 Saguenay \u2014 Lake St-John Region Tremblay, Jean-Marie, Case postale 40, Sacré-Coeur de Jésus, Saguenay (Québec) 05-10-73 Région du Nord-Ouest \u2014 North West Region Morin, Léo-Paul, Case postale 570, rue Notre-Damc-de-Lourdes, Ville-Marie, 01-10-72 Témiscamingue, (Québec) .Surkis, Max, 68, avenue des Pins, Lebel-sur-Quévillon, Abitibi, (Québec) 16-11-72 60742-o Liquidation \u2014 Loi de la Winding-Up Act GAUTHIER, DAGEN VIS, LEDOUX, TURCOTTE ET PELLETIER Avis suivant l'article 1896 a C.C.Avis est donné à tous les intéressés que, suivant jugement rendu le 18 mars 1975 par l'Honorable juge André Nadeau, suite à une requête portant le numéro 500-18-000283-755 de la Cour Supérieure du district de Montréal, Georges-Etienne Marchand, comptable agréé exerçant sa profession à titre d'associé de Price, Waterhouse & Cie, au 5, de la Place Ville-Marie, suite 720, à Montréal, a été nommé liquidateur de la société d'ingénieurs professionnels connue sous les nom et raison sociale de « GAUTHIER, DAGENAIS.LEDOUX, TURCOTTE ET PELLETIER », société qui opérait également sous les nom et raison sociale de « GUY GAUTHIER & ASSOCIES ».Montréal, le 24 mars 1975.60745-o Georges-Etienne Marchand.GAUTHIER, DAGENAIS, LEDOUX, TURCOTTE ET PELLETIER Notice according to section 1896 a C.C.To whom it may concern, take notice that following a judgment rendered on the eighteen of March, 1975, by Honorable Justice André Nadeau on a petition to that effect bearing number 500-18-000283-755 of the Superior Court, District of Montreal, Georges-Etienne Marchand, chartered accountant, practising in partnership with Price, Waterhouse & Cie, has been appointed liquidator of the partnership known under the name of \"GAUTHIER, DAGEN'AIS, LEDOUX, TURCOTTE, & PELLETIER, and also operated under the name of GUY GAUTHIER & ASSOCIES\".Montreal, March 24, 1975.60745-o Georges-Etienne Marchand.COOPERATIVE CENTRALE DE PECHEURS CENTRAL FISHERMEN'S CO-OPERATIVE (Loi des associations coopératives) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de l'association coopérative «COOPERATIVE CENTRALE DE PECHEURS -CENTRAL FISHERMEN'S CO-OPERATIVE», dont le siège social est situé à Cap-aux-Meulcs, dans le district électoral des Iles-de-la-Madeleine, tenue à Cap-aux-Meules le 12 décembre 1974, il a été résolu de liquider la coopérative et qu'elle soit dissoute, ce conformément aux dispositions de la Loi des associations coopératives et de la Loi de la liquidation des compa- Sies, et que MM.Yvon Turbide, John Arsenault et itonie Bourque soient nommés liquidateurs.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 60748-o Marc Carrier pour Albert Jessop.COOPERATIVE CENTRALE DE PECHEURS CENTRAL FISHERMEN'S CO-OPERATIVE (Cooperative Associations Act Notice is given that at a special general meeting of the members of the cooperative association \"COOPE-PATIVE CENTRALE DE PECHEURS - CENTRAL FISHERMEN'S CO-OPERATIVE\", whose head office is located in Cap-aux-MeuIes, in the Electoral District of the Magdalen Islands, held in Cap-aux-Mcules on December 12, 1974, it was resolved that the cooperative be wound up and that it be dissolved, the foregoing pursuant to the provisions of the Cooperative Associations Act and of the Winding-Up Act, and that Messrs.Yvon Turbidc, John Arsenault and Antonie Bourque be appointed liquidators.60748 Marc Carrier for Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives. 3680 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 8, 1975, Vol.107, No.18 Vente d'effets non réclamés Sale of Unclaimed Baggage LA CIE DES MESSAGERIES CP LIMITEE Avis est par les présentes donné que tous les effets reçus avant le 1er jour de juin, 1974, et non réclamés aux bureaux des CP Express limitée à divers endroits de la province de Québec, seront vendus aux enchères publiques au plus haut enchérisseur par Frank Wad-dington, encanleur, 189 est, rue Queen, Toronto, Ontario, à onze heures du matin, le 5e jour de juin, 1975, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.60755-18-6-o Le vice-président, W.M.Riley.CP EXPRESS LIMITED Notice is hereby given that all goods received previous to the first day of June, 1974, still remaining unclaimed in the offices of the CP Express Limited at different points in the Province of Québec, will- be sold at public auction to the highest bidder by Frank Wad-dington, auctioneer, at 189 Queen Street East, Toronto, Ontario, at eleven o'clock in the forenoon, on the fifth day of June, 1975, unless same shall be called for before that date and all charges paid thereon.60755-18-6-0 W.M.Riley, Vice-President.Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.» a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Oscar Giraldo, de Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 1010, rue Ste-Catherine ouest, bureau 333, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.60688-o 1361-7782 AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the said Company is Mr Oscar Giraldo, of Montreal.The principal office of the Company in the Province is located at 1010 Sainte-Catherine Street West, Office 333, Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60688 1361-7782 J.L.HOGG TRANSPORT LTD.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « J.L.HOGG TRANSPORT LTD.» a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Stuart H.Cobbett, 4, Place Ville-Marie, bureau 512, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 785, chemin St-Joseph, Bernières, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières compagnies et coopératives, Albert Jesop.60688-o 1362-0489 J.L.HOGG TRANSPORT LTD.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"J.L.HOGG TRANSPORT LTD.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the said company is Mr Stuart H.Cobbett, 4 Place Ville-Marie, Office 512, Montreal.The principal office of the company in the Province is located at 785 Saint-Joseph Road, Bernières, Judicial District of Québec.Albert Jessop, Deputy Minuter of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60688 1362-0489 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mai 1975, 107' année, n' 18 3681 MAJESTIC WILEY CONTRACTORS LIMITED MAJESTIC WILEY CONTRACTORS LIMITED Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « MAJESTIC WILEY CONTRACTORS LIMITED » a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.André Larivée, avocat, de Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 800, carré Victoria, bureau 3400, Tour de la Bourse, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.60688-o 1362-4168 Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"MAJESTIC WILEY CONTRACTORS LIMITED\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the said Company is Mr André Larivée, lawyer, of Montreal.The principal office of the Company in the Province is located at 800 Victoria Square, Office 3400, Stock Exchange Tower, Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60688 1362-4168 Société d'habitation du Québec Québec Housing Corporation Ville de Jonquière Programme de rénovation « Secteur Jonquière Centre-Ville » (Modifications) Avis est donné qu'en vertu de l'article 40 de la Loi de la Société d'habitation du Québec (L.Q.1966/1967, chapitre 55), le lieutenant-gouverneur en conseil a, par l'arrêté en conseil numéro 1482-75 en date du 11 avril 1975, ratifié les modifications adoptées par le règlement numéro 3 en date du 10 février 1975 de la ville de Jonquière à son programme de rénovation pour la partie de son territoire appelée « Secteur Jonquière Centre-Ville » et décrété « zone re rénovation » le territoire additionnel qui fait l'objet de ce programme.La Société d'habitation du Québec a, par sa résolution numéro 8291 en date du 24 mars 1975, approuvé ces modifications.Le secrétaire, 60746-o Me Jean-Luc Lesage, notaire.City of Jonquière Renewal program \"Secteur Jonquière Centre-Ville\" (M edifications) Notice is hereby given that pursuant to section 40 of the Québec Housing Corporation Act (1966/1967, Chapter 55), the Lieutenant-Governor in Council has, by Order number 1482-75 dated April 11, 1975, ratified the modifications adopted by by-law number 3 dated February 10, 1975, of the City of Jonquière in its renewal program for the part of its territory known as \"Secteur Jonquière Centre-Ville\", and declared a \"renewal zone\" the additional part of its territory covered by the program.The Québec Housing Corporation has, by its resolution number 8291 dated March 24,1975, approved these modifications.Me Jean-Luc Lesage, notary, 60746-o Secretary.Syndicats professionnels Professional Syndicates SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA REGION DES MILLE-ISLES (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 27 mars 1975, il a autorisé le changement de nom de « SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE LA REGION DES MILLE-ISLES », dont la constitution, sous le nom originaire SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA REGION DES MILLE-ISLES (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on March 27, 1975, he authorized the change of name of \"SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE LA REGION DES MILLE-ISLES\", whose incorporation was authorized on 3682 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May S, 1976, Vol.107, No.18 de l'« ASSOCIATION DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES DES DEUX-MONTAGNES », a été autorisée le 4 février 1953, et dont le siège social est situé à Saint-Eustache, en celui de « SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA REGION DES MILLE-ISLES », et ce, en vertu de la Loi des syndicats professionnels.Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 60729-o Albert Jessop.February 4, 1953 under the original name of \"ASSOCIATION DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES DES DEUX-MONTAGNES\", with its head office located in Saint-Eustache, to that of \"SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA REGION DES MILLE-ISLES\", the foregoing pursuant to the provisions of the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 146.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60729 Companies and Cooperatives.SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAPINS DE BOUCHERIE DU QUEBEC (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 14 mars 1975, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAPINS DE BOUCHERIE DU QUEBEC», avec siège social à Saint-Roch-de-l'Achigan, district judiciaire de Joliette.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.60730-o 1360-1679 SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAPINS DE BOUCHERIE DU QUEBEC (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on March 14, 1975, he authorized the incorporation of a professional syndicate, under the name of \"SYNDICAT DES PRODUC TEURS DE LAPINS DE BOUCHERIE DU QUE-BEC \", with its head office located in Saint-Roch-de-l'Achigan, Judicial District of Joliette.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60730 1360-1679 L'ASSOCIATION DES CHEFS DU SERVICE D'INCENDIE DE MONTREAL INC.(Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 14 mars 1975, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « L'ASSOCIATION DES CHEFS DU SERVICE D'INCENDIE DE MONTREAL INC.», avec siège social situé à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minxstre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.60737-o 1361-8004 L'ASSOCIATION DES CHEFS DU SERVICE D'INCENDIE DE MONTREAL INC.(Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on March 14, 1975, he authorized the incorporation of a professional syndicate, under the name of \"L'ASSOCIATION DES CHEFS DU SERVICE D'INCENDIE DE MONTREAL INC.\", with its head office located in Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60737 1361-8004 L'ASSOCIATION DES NOTAIRES D'ARTHABASKA, DRUMMOND ET MEGANTIC (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 26 mars 1975, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de «L'ASSOCIATION DES NOTAIRES D'ARTHABASKA, DRUMMOND ET MEGAN-TIC>, avec siège social situé à Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.60747-o SP.1361-4268 L'ASSOCIATION DES NOTAIRES D'ARTHABASKA, DRUMMOND ET MEGANTIC (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on March 26, 1975, he authorized the constitution of a professional syndicate under the name of \"L'ASSOCIATION DES NOTAIRES D'ARTHABASKA, DRUMMOND ET MEGANTIC\", with head office located in Victoriaville, Judicial District of Arthabaska.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60747 SP.1361-4268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mai 1975, 107' année, n° 18 3683 SYNDICAT DE L'U.P.A.DE ROUVILLE (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 6 mars 1975, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « SYNDICAT DE L'U.P.A.DE ROUVILLE », avec siège social situé à Marieville, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.6073l-o 1360-7072 Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.BEDFORD Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Bedford ( T ÉONARD LAPORTE, de-No 455-05-000468-74.-^ ¦L' mandeur, vs MARIO v BENOIT, défendeur.« Un terrain sis et situé à Ste-Anne-de-la-Rochelle, du Côté nord d'un chemin public (ancienne route 39), faisant partie du lot six cent trente et un (Ptie 631) du cadastre officiel du canton Stukely, mesurant quatre-vingts pieds (80') (en front sur le chemin public) et vingt pieds (20') dans ses lignes sud, deux cents pieds (200') dans sa ligne ouest, cent pieds (100') dans sa ligne nord, cent vingt-cinq pieds (125') et soixante-quinze pieds (75') dans ses lignes est.Ce terrain est borné comme suit: vers le sud par le chemin public et par une partie du lot 631 appartenant à Jean-René Brien, vers l'ouest par une autre partie dudit lot 631 appartenant à Léonard Laporte, vers le nord par une autre partie dudit lot 631 appartenant à Gérard Brouillette et vers l'est par des parties du lot 631 appartenant à Jean-René Brien et à Gérard Brouillette.Avec la maison y édifiée, ses circonstances et dépendances.» Pour erre vendu au bureau d'enregistrement de Shefford, à Waterloo, district de Bedford, MERCREDI, le ONZIÈME jour de JUIN 1975, à TROIS heures de l'après-midi.Cowansville, ce 23 avril 1975.Le shérif, 60751-o Antonin Bourassa.SYNDICAT DE L'U.P.A.DE ROUVILLE (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on March 6, 1975, he authorized the incorporation of a professional syndicate, under the name of \"SYNDICAT DE L'U.P.A.DE ROUVILLE\", with its head office located in Marieville, Judicial District of Saint-Hyacinthe.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60731 1360-7072 Sheriff's Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.BEDFORD Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Bedford l T ÉONARD LAPORTE, No.455-05-000468-74X *-> plaintiff, vs MARIO BE- t NOIT, defendant.\"A piece of land lying and situate in Sainte-Anne-de-la-Rochelle, on the north side of a public road (former Highway 39), forming part of lot six hundred thirty-one (Pt.631) on the official cadastre for the Township of Stukely, measuring eighty feet (80') (in front on the public road) and twenty feet (20') on its south lines, two hundred feet (200') on its west line, one hundred feet (100') on its north line, one hundred twenty-five feet (125') and seventy-five feet (75') in its east lines.This piece of land is bounded as follows: towards the south by the public road and by a part of lot 631 belonging to Jean-René Brien, towards the west by another part of said lot 631 belonging to Léonard Laporte, towards the north by another part of said lot 631 belonging to Gérard Brouillette and towards the east by parts of lot 631 belonging to Jean-René Brien and Gérard Brouillette.With the house erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Shefford Registry Office, in Waterloo, District of Bedford, on WEDNESDAY, the ELEVENTH day of JUNE, 1975, at THREE o'clock in the afternoon.Cowansville, April 23, 1975.Antonin Bourassa, 60751 Sheriff. 3684 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1976, Vol.107, No.18 Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Montréal I /CRITERION INSTRUMENTS No 412-898-71.< LIMITED, demanderesse, vs v MOSTAFA EL-KASTAUI, défendeur.« Les lots 524-37, 530-49, 530-50, 530-Ptie 81, 530-82, aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Granby, avec dépendances et bâtisses y érigées, situés au 251, Avenue Hillview, Granby, Québec.» Pour être vendus au bureau d'enregistrement de Shefford, à Waterloo, district de Bedford, MERCREDI, le ONZIÈME jour de juin 1975, à DEUX heures de l'après-midi.Le shérif, Antonin Bourassa.Cowansville, ce 23 avril 1975.60752-o Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Montreal C /CRITERION INSTRUMENTS No.412-898-71X ^ LIMITED, plaintiff, vs MOS-l TA FA EL-KASTAUI.defendant.\"Lots 524-37, 530-49, 530-50, 530-Pt.81, 530-82 on the official plan and in the book of reference for the Township of Granby, with dependencies and buildings erected thereon, located at 251 Hillview Avenue, Granby, Québec.\" To be sold at the Shefford Registry Office, in Waterloo, District of Bedford, on WEDNESDAY, the ELEVENTH day of JUNE, 1975, at TWO o'clock in the afternoon.Antonin Bourassa.Sheriff.Cowansville, April 23, 1975.60752 MONTMAGNY Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montmagny (T\\AME DOLORÈSE THERR1EN No 11-990 S -L-' BRETON, domiciliée et résidant l à 2213 des Pruches, app.2, Orsainville, district de Québec, demanderesse, ti* RÉAL BRETON, domicilié et résidant à Daaquam, district de Montmagny, défendeur.« Partie du lot no 12, Rang VI, Canton Panet ».Pour être vendu au bureau du registrateur de Montmagny, au Palais de Justice de Montmagny, JEUDI, le CINQUIÈME jour du mois de JUIN 1975, à TROIS heures de l'après-midi.Le shérif.Bureau du shérif, Jean-Paul Tremblay.Montmagny, 22, avril 1975.60711-0 Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Montmagny ( T A COMMISSION DU SA-No 300-02-000343-74.< LAIRE MINIMUM, >¦ Hôtel du Gouvernement, Québec, demanderesse, vs SCIERIE DU GALLION INC., corporation légalement constituée ayant son siège social à Ste-Perpétue, comté LTslet, district de Montmagny, défenderesse.« Un immeuble désigné comme étant le lot numéro onze (11), subdivision A, rang A, Lafontaine.Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro onze (11), subdivision C.P., rang A, Garneau, à Ste-Perpétue.Le lot numéro onze (11), subdivision D.P., rang A, Garneau, à Ste-Perpétue, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances ».MONTMAGNY Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montmagny (\\/fRS.DOLORÈSE THERRIEN No.11-990 < J-Vl BRETON, domiciled and resi-l ding at 2213 Des Pruches, Apt 2, Orsainville, District of Québec, plaintiff, vs RÉAL BRETON, domiciled and residing at Daaquam, District of Montmagny, defendant.\"Part of lot No.12, Range VI, Township of Panet\".To be sold at the Office of the Registrar of Montmagny, at the Montmagny Court House, on THURSDAY, the FIFTH day of the month of .TUNE, 1975, at THREE o'clock in the afternoon.Jean-Paul Tremblay, Sheriff's Office, Sheriff.Montmagny, April 22, 1975.60711 Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Montmagny I THE MINIMUM WAGE No.300-02-000343-74X J- COMMISSION, Parlia-l ment Buildings.Québec, plaintiff, es SCIERIE DU GALLION INC., a corporation legally incorporated, having its head office in Sainte-Perpétue, County of LTslet, District of Montmagny, defendant.\"An immoveable described as being lot number eleven (11), subdivision A, in Range A, Lafontaine.An immoveable known and described as being lot number eleven (11), subdivision C.P., in Range A, Garneau, in Sainte-Perpétue.Lot number eleven (11), subdivision D.P., in Range A, Garneau, Sainte-Perpétue, with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mai 1975, 107\u2022 année, n' 18 3685 Pour être vendu au bureau d'enregistrement de St-Jean-Port-Joli, MARDI, le TROISIÈME jour de JUIN 1975, à TROIS heures de l'après-midi.Bureau du shérif.Le shérif.Palais de Justice, Jean-Paul Tremblay.Montmagny, Que., 22 avril 1975.60710-o To be sold at the Saint-Jean-Port-Joli Registry Office, on TUESDAY, the THIRD day of JUNE, 1975, at THREE o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Jean-Pail Tremblay, Court House, Sheriff.Montmagny.Québec, April 22, 1975.60710 MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Montréal !T>ANQUE CANADIENNE NA-O TIONALE, corporation légalement constituée, ayant son siège social dans les cité et district de Montréal, demanderesse, M PIERRE-YVES LAN1EL, domicilié au 4426, rue Dupuis, Pien-efonds, Québec, défendeur.« Un emplacement ayant front sur la rue Dupuis, en la cité de Pierrefonds, composé comme suit: 1.Du lot numéro trente-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-un (181-36), du cadastre de la paroisse de Ste-Geneviève, mesurant cedit lot soixante et un pieds (61') de largeur par quatre-vingt-cinq pieds et quatre-vingt-quatorze centièmes de pied (85.94') de profondeur dans sa ligne nord-ouest et quatre-vingt-sept pieds et soixante-six centièmes de pied (87-66') de profondeur dans sa ligne sud-est, contenant une superficie totale de cinq mille deux cent quatre-vingt-quatorze pieds carrés (5,294').2.Et de la partie nord-ouest du lot numéro trente-sept de la subdivision officielle dudit lot originaire numéro cent quatre vingt-un (181 ptie no 37) susdit cadastre, mesurant cettedite partie deux pieds et cinq dixièmes de pied (2.5') de largeur par quatre-vingt-sept pieds et soixante-six centièmes de pied (87.66') de profondeur dans sa ligne nord-ouest et quatre-vingt-sept pieds et soixante-treize centièmes de pied (87.73') de profondeur dans sa ligne sud-ouest, contenant une superficie totale de deux cent dix-neuf pieds carrés et vingt-quatre centièmes de pied (219.24' pi.ca.) et bornée comme suit: vers le nord-est par le lot no 181-7 étant la rue Dupuis; vers le sud-est par la partie sud-est dudit lot no 181-37; vers le sud-ouest par le lot no 182-43, susdit cadastre; et vers le nord-ouest par le lot no 181-36 ci-haut en premier lieu décrit.Le tout avec bâtisses dessus érigées portant le numéro civique 4426, rue Dupuis, en la cité de Pierrefonds.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice de Montréal.10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le TROISIÈME jour de JUIN 1975, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du shérif.Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 22 avril 1975.60721-o MONTREAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Montreal iTJANK CANADIAN NATIO-¦L,NAL.a corporation legally incorporated, having its head office in the City and District of Montreal, plaintiff, M PIERRE-YVES LANIEL.domiciled at 4426 Dupuis Street.Pierrefonds, Québec, defendant.\"An emplacement fronting on Dupuis Street, in the City of Pierrefonds, comprising the following: 1.Lot number thirty-six of the official subdivision of original lot number one hundred eighty-one (181-36) on the cadastre for the Parish of Sainte-Geneviève, the said lot measuring sixty-one feet (61') in width by a depth of eighty-five and ninety-four hundredths feet (85.94') on its northwest line and a depth of eighty-seven and sixty-six hundredths feet on its southeast line, covering a total area of five thousand two hundred ninety-four square feet (5,294 sq.ft.).2.And the northwest part of lot number thirty-seven of the official subdivision of said original lot number one hundred eighty-one (181 Pt.No.37) on said cadastre, the said part measuring two and five tenths feet (2.5') in width by eighty-seven and sixty-six hundredths feet (87.66') in depth on its northwest line and eighty-seven and seventy-three hundredths feet (87.73') in depth on its southwest line, covering a total area of two hundred nineteen and twenty-four hundredths square feet (219.24 sq.ft.) and bounded as follows: towards the northeast by lot No.181-7 being Dupuis Street; towards the southeast by the southeast part of said lot No.181-37; towards the southwest by lot No.182-43, on said cadastre; and towards the northwest by lot No.181-36 first described hereinabove.The whole with the buildings erected thereon, bearing civic number 4426 Dupuis Street, in the City of Pierrefonds.\" To be sold at the Sheriff's Office, at the Montreal Court House.10 Craig Street East, 10th floor.Room 56, on the THIRD day of JUNE, 1975, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, April 22, 1975.60721 3686 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.18 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal (TVME EGLANTINE PI-No 05-00 8606-72.< ¦L' G EON.domiciliée et rési- ' dant au 6500, 13e Avenue, Rosemont, cité et district de Montréal, demanderesse, H GÉRARD LABELLE.domicilié et résidant au 1301, rue Bruxelles, cité et district de Montréal, défendeur.« Un emplacement portant sur les lots soixante-dix-huit et soixante-dix-neuf, de la subdivision officielle du lot originaire trois cent quatre-vingt-onze (391-78-79) du cadastre officiel de la paroisse de la Longue-Pointe, avec bâtisse desus érigée et portant le numéro 1301, de la rue Bruxelles, à Montréal, tel que le tout se trouve présentement, » Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, Montréal, P.Q., le QUATRIÈME jour de JUIN 1975, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du shérif.Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 22 avril 1975.60723-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province dc Québec Cour Supérieure \u2014 District de Québec I T 'ASSURANCE VIE DESJAR-No 05-00 4290-74X DINS, corporation légale- l ment constituée, ayant son siège social au 200, avenue des Commandeurs, Lévis, P.Q., demanderesse, m B.DENIS BROSSARD, comptable, domicilié et résidant au 112, rue St-Laurent, Laprai.'ie, district de Montréal, défendeur, et LE REGISTRA-TEUR de la division d'enregistrement de Laprairie.mis en cause.« Un emplacement situé en la ville de Laprairie, connu et désigné comme étant le lot numéro quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro quarante et un (41-4) au cadastre officiel du village de Laprairie.Avec une maison ci-dessus érigée et portant le numéro civique 112, rue Saint-Laurent.Sujet à une servitude dc passage tel qu'il appert par acte passé devant Me Jean Brossard, notaire, le 22 janvier 1955, et dont copie fut enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Laprairie.sous le numéro 45434, et à une autre servitude de vue tel qu'il appert par acte passé devant le notaire soussigné, le 7 juin 1966, et dont copie sera enregistrée au susdit bureau d'enregistrement incessamment.Tel que le tout se trouve présentement.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laprairie, 214, St-Ignace, Laprairie, P.Q., le TROISIÈME jour de JUIN 1975, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du shérif, Le shérif adjoint, Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 22 avril 1975.60720-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court\u2014 District of Montreal fXyfRS.EGLANTINE PI-No.05-00 8606-72X *V1 G EON, domiciled and re-l siding at 6500 - 13th Avenue, Rosemont, City and District of Montreal, plaintiff, M GÉRARD LABELLE, domiciled and residing at 1301 Bruxelles Street, City and District of Montreal, defendant.\"An emplacement comprising lots seventy-eight and seventy-nine of the official subdivision of original lot three hundred and ninety-one (391-78-79) on the official cadastre for the Parish of Longue-Pointe, with a building erected thereon and bearing civic number 1301 Bruxelles Street, in Montreal, as the whole presently subsists.\" To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House of Montreal.10, Craig Street East, 10th Floor, Room 56, Montreal, P.Q.on the FOURTH day of JUNE, 1975, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Mahtin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, April 22, 1975.60723 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Québec I T 'ASSURANCE VIE DESJAR-No.05-00 4290-74.< J-* DINS, a corporation legally t incorporated, having its head office at 200 Des Commandeurs Avenue, Lévis, P.Q., plaintiff, vs B.DENIS BROSSARD, accountant, domiciled and residing at 112 Saint-Laurent Street, Laprairie, District of Montreal, defendant, and THE REGISTRAR for Laprairie Registration Division, mis en cause.\"An emplacement located in the Town of Laprairie, known and described as being lot number four of the official subdivision of original lot number forty-one (41-4) on the official cadastre for the Village of Laprairie.With a house erected thereon and bearing civic number 112 Saint-Laurent Street.Subject to a servitude of right of way as it appears in a deed executed before Me Jean Brossard, notary, on January 22,1955, a copy of which has been registered at the Office of Laprairie Registration Division, under number 45434, and to another servitude of view as it appears in a deed executed before the undersigned notary, on June 7, 1966, a copy of which shall be registered forthwith at the said Registry Office.As the whole now subsists.\" To be sold at the Laprairie Registry Office, 214 Saint-Ignace, Laprairie, P.Q., on the THIRD day of JUNE, 1975, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, PAUL St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, April 22, 1975.60720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1975.107- année, n' 18 3687 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal | \"FIDUCIAIRES DE LA CITE No 05-013 129-74X 1 ET DU DISTRICT DE l MONTREAL LIMITEE, corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 1253, McGill College, à Montréal, district judiciaire de Montréal, demanderesse, vs FRANÇOIS CONSTRUCTION LIMITEE, corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 150, boulevard des Ormeaux, à Longueuil, district judiciaire de Montréal, défendeur, et JACQUES COOKE, résidant et domicilié au 150, boulevard des Ormeaux à Longueuil, district judiciaire de Montréal, DAME REJEANNE TREMBLAY, résidant et domiciliée au 150 boulevard des Ormeaux, à Longueuil, district judiciaire de Montréal, ANDRE STE-MARIE, résidant et domicilié au 9017, rue Provencher, à St-Léonard, district judiciaire de Montréal, co-défendeurs, LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Chambly, à Longueuil, district judiciaire de Montréal, mis en cause.« Un emplacement ayant front sur l'avenue Lavallée, dans la ville de Longueuil, connu et désigné sous le lot numéro six cent quarante-cinq de la subdivision du lot originaire numéro quatre-vingt-cinq (85-645) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Antoine-de-Longueuil, division d'enregistrement de Chambly.Mesurant cent soixante-trois pieds (163') dans sa ligne nord; cent trente pieds (130') dans sa ligne est; quatre-vingt-onze pieds et soixante-trois centièmes de pied (91.63') dans sa ligne sud; soixante-douze pieds et cinq centièmes de pied (72.5') dans sa ligne sud-ouest et cent vingt pieds et quatre centièmes de pied (120.04') dans sa ligne ouest.Contenant en superficie vingt mille huit cent trente-quatre pieds carrés (20,834 pi.ca.) et: Borné comme suit: Au nord par le lot 85-628 (avenue Lavallée), à l'est par le lot 85-646, au sud par le lot 85-627-3, au sud-ouest par une partie non subdivisée du lot numéro 85-627-2 et à l'ouest par le lot numéro 85-644, tous dudit cadastre.Avec maison dessus érigée et portant le numéro civique 1450, avenue Lavallée, ville de Longueuil, dont tous les murs sont indépendants.Tel que le tout se trouve présentement avec tous ses droits, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve de la part de l'emprunteur et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit emplacement, et notamment celles créées en faveur de l'Hydro-Québec et la Compagnie de Téléphone Bell du Canada, dans un acte passé devant Me J.G.Brissette, notaire, le 6 décembre 1957, et enregistré à Chambly sous le numéro 171,099, et également au sujet à une autre servitude telle que mentionnée dans un acte passé devant Me J.A.Senay, notaire, le 27 décembre 1956 et enregistre à Chambly sous le numéro 162,962 et aussi sujet à une servitude créée en faveur de Steinberg's Ltd., créée dans un acte Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal i \"MONTREAL CITY AND DIS-No.05-013 129-74X 1V1 TRICT TRUSTEES LIM- ' ITED, a corporation legally incorporated, having its business office at 1253 McGill College, in Montreal, Judicial District of Montreal, plaintiff, vs FRANÇOIS CONSTRUCTION LIMITEE, a corporation legally incorporated, having its business office at 150 des Ormeaux Boulevard, in Longueuil, Judicial District of Montreal, defendant, and JACQUES COOKE, residing and domiciled at 150 Des Ormeaux Boulevard, in Longueuil, Judicial District of Montreal, MRS.RÉJEANNE TREMBLAY, residing and domiciled at 150 Des Ormeaux Boulevard, in Longueuil, Judicial District of Montreal, ANDRÉ STE-MARIE, residing and domiciled at 9017 Provencher Street, in Saint-I-éonard, Judicial District of Montreal, joint defendants, THE REGISTRAR for the Chambly Registration Division, in Longueuil, Judicial District of Montreal, mit en cause.\"An emplacement fronting on Lavallée Avenue, in the City of Longueuil, known and described as lot number six hundred forty-five of the subdivision of original lot number eighty-five (85-645) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Saint- Antoine-de-Longueuil, Chambly Registration Division.Measuring one hundred sixty-three feet (163') on its north line; one hundred thirty feet (130') on its east line; ninety-one and sixty-three hundredths feet (91.63') on its south line; seventy-two and five tenths feet (72.5') on its southwest line and one hundred twenty and four hundredths feet (120.04') on its west line.Covering an area of twenty thousand eight hundred thirty-four square feet (20,834 sq.ft), and: Bounded as follows: On the north by lot 85-628 (Lavallée Avenue), on the east by lot 85-646, on the south by lot 85-627-3, on the southwest by a nonsubdivided part of lot number 85-627-2, and on the west by lot number 85-644, all on the same cadastre.With a house erected thereon bearing civic number 1450 Lavallée Avenue, City of Longueuil, with independent walls.As the whole presently subsists with all its rights, appurtenances and dependencies, without exception or reservation on the part of the borrower, including all active and passive, apparent and unapparent servitudes attaching to said emplacement, namely the servitudes established for the benefit of Hydro-Québec and of the Bell Telephone Company of Canada, under the terms of a deed executed before Me J.-G.Brissette, notary, on December 6, 1957, and registered in Chambly under number 171,099, also subject to another servitude which is mentioned in a deed executed before Me J.-A.Senay, notary, on December 27, 1956 and registered in Chambly under number 162,962, and also subject to a servitude established for the 3688 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 3, 1975, Vol.107, No.18 de vente passé devant le notaire soussigné le 25 mai 1973, et enregistré à Chambly sous le numéro 382,747.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Chambly, 201, Place Charles-Lemoyne, Édifice Montval, à Longueuil, P.Q., le QUATRIÈME jour de JUIN 1975, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du shérif.Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 23 avril 1975.60722-o QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: f.T>OITEAU INC., corpora-Cour Provinciale, ) ¦L' tion légalement consti-No 200-02-001156-753.J tuée ayant une place d'affai-' res à Québec, vs Mme MARGUERITE BLACKBURN, résidant à 2765, rue Morgan.Ste-Foy, P.Q.« La resubdivision numéro un de la division numéro soixante-neuf du lot originaire numéro trois cent sept (307-69-1) du cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Foy, division d'enregistrement de Québec, avec maison y érigée, portant le numéro civique 2765, rue Morgan en la ville de Ste-Foy, circonstances et dépendances.Le mur nord-est de ladite maison est mitoyen avec le mur sud-ouest de la propriété construite sur le lot 307-69-2 dudit cadastre.» Pour être vendu au buieau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, le SIXIÈME jour de JUIN 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 28 avril 1975.60750-o Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: [TA CAISSE POPULAIRE Cour Provinciale, ) J-' DE VILLENEUVE, so-No 200-02-009100-746.1 ciété régie par la I-oi des ' caisses d'épargne et de crédit, 1095, boul.des Chutes.Villeneuve, vs ANDRÉ TRU-DEL, 55, Jean-de-Brébeuf, Lauzon, et LE REGIS-TRATEUR du bureau d'enregistrement division Lévis, mis en cause.« Un immeuble connu et désigné comme étant la redivision quarante-six de la subdivision un du lot originaire nunéro quarante-neuf (lot 49-1-46) du cadastre officiel pour la paroisse de St-Joseph-de-Lévis, division d'enregistrement de Lévis, avec bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Lévis, 113.rue St-Georges ouest, Lévis, le SIXIÈME jour de JUIN 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 28 avril 1975.60749-o benefit of Steinberg's Ltd., created under the terms of a deed of sale executed before the undersigned notary, on May 25, 1973, and registered in Chambly under number 382,747.\" To be sold at the County of Chambly Registry Office, 201 Place Charles-Lemoyne, Montval Building, in Longueuil, P.Q., on the FOURTH day of JUNE, 1975, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, April 23, 1975.60722 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit: ( T50ITEAU INC., a corpo-Provincial Court, ) ration legally incorpo-No.200-02-001156-753.1 rated, having a place of f, business in Québec, vs Mrs.MARGUERITE BLACKBURN, residing at 2765 Morgan Street, Sainte-Foy, P.Q.\"Resubdivision number one of division number sixty-nine of original lot number three hundred seven (307-69-1) on the official cadastre for the Parish of Sainte-Foy, Québec Registration Division, with a house erected thereon, bearing civic number 2765 Morgan Street, in the City of Sainte-Foy, appurtenances and dependencies.The northeast wall of the said house is common with the southwest wall of the property erected on lot 307-69-2 of said cadastre.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St-Pierre Street, Québec, on the SIXTH day of JUNE, 1975, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriffs' Office, Assistant Sheriff.Québec, April 28, 1975.60750 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: ( T A CAISSE POPULAIRE Provincial Court ) DE VILLENEUVE, a No.200-02-009100-746) union governed by the Sav-\\ ings and Credit Unions Act.1095 Des Chutes Boulevard, Villeneuve, vs ANDRE TRUDEL, 55 Jean-de-Brébeuf, Lauzon, and THE REGISTRAR for the Levis Division Registry Office, mis en cause.\"An immoveable known and described as being redivision forty-six of subdivision one of original lot number forty-nine (lot 49-1-46) on the official cadastre for the Parish of Saint-Joseph, in Levis, Levis Registration Division, with a building erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Levis Registry Office, 113 St-Georges Street West, Levis, on the SIXTH day of JUNE, 1975, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Rolland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, April 28, 1975.60749 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mai 1976, 107' année, n' 18 3689 RIMOUSKI Fieri Facial de Terril Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Rimouski ( \"pvAME DANIELLE GAGNÉ No 120-02-002-74.< et DENIS OUELLET, do- ' miciliés à 210, St-André, Rivière-du-Loup, comté et district de Témiscouata, demandeurs, vs FRANÇOIS JEAN, domicilié à Ste-lrène, comté de Matapédia, P.Q., défendeur.Partie du lot 17-C, rang 5, canton Nemtayé, Ste-lrène, comté de Matapédia.Pour être vendu au bureau d'enregistrement, district de Rimouski, en la ville d'Amqui au numéro 27, boulevard St-Benott, le VINGTIEME jour de JUIN 1975, à DEUX heures de l'après-midi.Le ihêrif adjoint.Bureau du shérif, Bertrand Doyon.Rimouski, ce 15e jour d'avril 1975.60712-o RIMOUSKI Fieri Facial de Terril Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Rimouski {\\ÂRS.DANIELLE GAGNÉ No.120-02-002-74.< J-Vl and DENIS OUELLET, I domiciled at 210 Saint-André, Rivière-du-Loup, County and District of Témiscouata, plaintiffs, va FRANÇOIS JEAN, domiciled in Sainte-Irène, County of Matapédia, P.Q., defendant.Part of lot 17-C, in Range 5, Township of Nemtayé, Sainte-Irène, County of Matapédia.To be sold at the Registry Office, District of Rimouski, in the Town of Amqui, at 27 Saint-Benoit Boulevard, on the TWENTIETH day of JUNE, 1975, at TWO o'clock in the afternoon.Bertrand Doyon, Sheriff's Office, Astittant Sheriff.Rimouski, this 15th day of April, 1975.60712 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Rimouski [EAN-BAPTISTE LARRIVÉE, con- Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Rimouski EAN-BAPTISTE LARRIVÉE, con- l JEAN-BAPTISTE LARRIVÉE, con- / JEAN-BAPTISTE LARRIVÉE, con- No S-1791.\\ J tracteur, domicilié à Cap-Chat, dans No.S-1791.\\ J tractor, domiciled in Cap-Chat, in the ' le district de Gaspé, demandeur, vs \" District of Gaspé, plaintiff, vi GER- GERMAIN ISABEL, domicilié à Les Méchins, district de Rimouski, défendeur.Un immeuble propriété du défendeur, sis et situé rang I, canton Dalibaire, du cadastre officiel de la municipalité de Les Méchins pour la somme de SI ,295.38.Cet immeuble est situé sur un terrain, lequel terrain est à Les Méchins, mesurant 220 pieds au nord, 183 pieds au sud, 165 pieds à l'est et 85 pieds à l'ouest, mesure anglaise, borné au nord par la nouvelle route no 6, au sud et à l'ouest, pai la rivière et à l'est par le résidu du lot 8-D-2, propriété de Victor Lavoie, connu comme faisant partie de la subdivision deux du lot huit-D (Ptie.8-D-2) du premier rang au cadastre officiel révisé du canton Dalibaire, avec maison dessus construite, circonstances et dépendances.Pour être vendu au bureau d'enregistrement, district de Rimouski, en la ville de Matane au numéro 382 de la rue St-Jérôme, le TREIZIÈME jour de JUIN 1975.à DEUX heures de l'après-midi.Le shérif adjoint, Bureau du shérif, Bertrand Doyon.Rimouski, ce 15e jour d'avril 1975.60713-o MAIN ISABEL, domiciled in Les Méchins, District of Rimouski, defendant.An immoveable owned by the defendant, lying and situate in Range I, Township of Dalibaire, on the official cadastre of the Municipality of Les Méchins, for the sum of $1,295.38.Said immoveable is erected on a piece of land, the whole located in Les Méchins, measuring 220 feet on the north, 183 feet on the south, 165 feet on the east and 85 feet on the west, English measure, bounded on the north by the new Highway No.6, on the south and west by the river and on the east by the remainder of lot 8-D-2, property of Victor Lavoie, known as forming part of subdivision two of lot eight-D (Pt.8-D-2) in the First Range, on the revised official cadastre for the Township of Dalibaire, with the house erected thereon, appurtenances and dependencies.To be sold at the Registry Office, District of Rimouski, in the Town of Slatane, at 382 Saint-Jérôme Street, on the THIRTEENTH day of JUNE.1975.at TWO o'clock in the afternoon.Bertrand Doyon, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Rimouski, this 15th day of April, 1975.60713 3690 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May S, 1975, Vol.107, No.18 SAINT-HYACINTHE Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de St-Hyacinthe ( T A CAISSE D'ETABLIS-No 750-05-000391-74.-C J-< SEMENT DE ST- 59\" (101.6 ' 149.8 cm) 1975 Représente les dix ( 10) régions administratives officielles du Gouvernement du Québec EOQ 2157 S 2.00 Les Parcs du Québec Carte murale sur papier en 10 couleurs Échelle: 1: 1 250 000 (approx 20 milles au pouce) Format: 40\" x 59\" (101.6 x 149.8 cm) 1975 Représente les parcs, les réserves, les terrains de camping, les kiosques d'information touristique et les centres piscicoles sous la juridiction du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche du Québec, de même que les parcs nationaux de Forillon.Gatineau.La Mauncie et la réserve du Cap Tourmente.EOQ 2158 S 2.00 Service des exploitations forestières Instructions et règlements officiels concernant le mesurage des bois provenant des terres publiques / Oflicial Instructions and Regulations Concerning the Scaling of Wood Cut on Public Lands Québec.1971 (1974).160 p., format de poche ISBN 0-7754-2164-2.cartonnée toile S 2.00 Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre Commission des accidents du travail de Québec Rapport annuel 1973 Québec.1974 53 p.tabl.graph.24 cm ISBN 0-7754-2168-5, broché S 1.00 S 4.00 \u2022 L'ÉDITEUR OFFICIEL W DU QUÉBEC 675 est; BOUL.ST-CYRILLE QUÉBEC SOMMAIRE Association's coopératives.3583 Avis divers.3580 Changement de nom, Loi du.3573-3653 Commission des transports du Québec.3590 Compagnies, Avis concernant la Loi des.3525-3692 Compagnies étrangères, Loi des.3680 Curatelle publique.3584 Demandes à la Législature.3665 Liquidation, Loi de la.3679 Ministères.3574-3582-3669 Proclamation.3588 Régie de l'assurance-maladie.3671 Société d'habitation du Québec.3681 Soumissions.3654-3691-3693 Syndicats professionnels.3681 Ventes : Effets non réclamés.3680 Par shérifs.3683 Pour taxes.3546 SUMMARY Applications to Legislature.3665 Change of Name Act.3573-3653 Companies Act, Notices concerning the.3525-3692 Cooperative Associations.3583 Departments.3574-3582-3669 Extra-Provincial Companies Act.3680 Miscellaneous Notices.3580 Proclamation.3588 Professional Syndicates.3681 Public Curatorship.3584 Québec Health Insurance Board.3671 Québec Housing Corporation.3681 Québec Transport Commission.3590 Sales: By Sheriffs.3683 For taxes.3546 Unclaimed goods.3680 Ten ders.3654-3691-3693 Winding-Up Act.3679 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec Cité parlementaire, Québec G1R 4Y7 1*\tCanada Postes Post Canada J \tThird Troisième \tclass classe \tPermis No.107 \tQuébec Montréal 129, Que.Bibliothèque Nationale Dép6t Légal 1700, St-Deni3 H2X 3K6 Outil de travail indispensable à tout homme d'affaires transigeant avec la France.Comprend notamment des informations sur les ministères et organismes gouvernementaux, les départements, la liste des si-gles employés couramment, etc.1974, 516 pages, 21 cm.EOQ.7413, cartonné toile $10.Éditeur officiel du Québec 675 est.Boul.Saint-Cyrille Québec.P.O.G1R 4Y7 "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.