Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 10 mai 1975, Partie 1 samedi 10 (no 19)
[" qpp JURIDIQUES E3A1 TE1 G3/ 3ICAL NOTICES ex.2 107e ANNÉE 10 MAI 1975 No 19 OFF /)//£& 4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC \t\t\t\tL 71\t1 IL\u2014\t\t\tj 1\u20141 PARTIE 1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 PART 1 .3707 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mardi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le iundi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Quebec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Tuesday noon; if Tuesday is a holiday, the deadline is Monday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher 3708 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May JO, J97Ô, Vol.107, No.19 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante : Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dube.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Quebec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec.Cité Parlementaire, Québec G1R 4Y7, P.Q.For information concerning the publication of notices, please call : (ieorges Lapierre Québec Officiai Gazette Tel.: (418) 643-5195 Off-prints or subscription rates: Tel.: (418) 643-5150 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1R 4Y7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1976, 107' année, n° 19 3709 AVIS JURIDIQUES\tJURIDICAL NOTICES\t Compagnies \u2014 Loi des\tCompanies Act\t Lettres patentes (1™ partie)\tLetters Patent (Part I)\t Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating:\t Nom / Name\tSiège social / Head Office\tIncorporation Date ADMINISTRATION QTJEROCH INC.et sa version anglaise QUEROCH MANAGEMENT INC.1371-5412\tdes-Monts\t28 02 76 AGENCE DE RECOUVREMENT R.M.BEATJLIETJ INC\t\t 1370-0034\t\t AGENCES SOMRO LTEE.\t\t et sa version anglaise SOMRO AGENCIES LTD.1371-2989\t\t AGENCE DE VENTES CLAUDE BELAND INC.\t\t18 02 75 1371-3748\t\t AMEUBLEMENT P.N.C.INC.\t\t et 6a version anglaise P.N.C.FURNITURE INC.1361-9432\t\t ANTIROUILLE TRU-GUARD (QUEBEC) LIMITEE et sa version anglaise TRU-GUARD RUSPROOFING (QUEBEC) LIMITED 1362-0620\tbureau 3900, Montréal.\t26 02 75 EMILE ARBOUR INC.1362-4432\t.1010, Lac-Cloutier sud, Sainte-Béatrix.\t17 03 75 MICHEL ARCHAMBAULT INC.1371-7541\tSaint-Lin.\t17 03 75 ARCHER, SEADEN & ASSOCIES INC.2050, rue Mansfield, Montréal.30 12 74 et sa version anglaise ARCHER, SEADEN & ASSOCIATES INC.1361-0308 ARMOIRES DE CUISINE CANDIAC INC.Candiac.20 03 76 1371-7921 L'ARTISANAT DE MEUBLES H.F.V.INC.87, chemin du Petit-Bois, Lorraine.10 03 76 1371-6626 ASSURANCES J.ARMAND LANDRY INC.46, rue Commerciale, Cabano.08 03 75 1362-2287 ASSURANCES J.THIBAULT INC.14, rue Beaudry, Saint-Constant.17 03 76 et sa version anglaise J.THIBAULT ASSURANCES INC.1371-7426 ASSURANCES JACQUES HEBERT INC.1371-5263 11763, rue Laurier, Montréal-Nord.28 02 76 3710 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10, 1975, Vol.107, No.19 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date ASSURANCES ROBERT DIONNE INC.1361-6313 ATELIERS CAN A V AC LTEE.et sa version anglaise CANAVAC SHOPS LTD.1371-7293 AUBERGE DE NOS AÏEUX INC.1371-6469 AUTO ELECTRIQUE B.& C.(1975) INC.et sa version anglaise B.& C.ELECTRIC AUTO 0975) INC.1359-9295 AUTOBUS L.S.B.C.INC.1362-0711 AUTOMATION A.D.QUEBEC INC.1362-8656 AUTOMOBILES LION INC.et sa version anglaise LION AUTOMOBILES INC.1371-6261 AUX FOYERS CHALEUREUX INC.1371-0827 BAR LA CEDULE INC.1371-6493 LES BATEAUX DE PECHE DU CAPITAINE JEAN INC.1362-0927 BERNITEUR INC.1361-8566 BIJOUTERIE CHARESTAN INC.1362-2873 BIJOUTERIE EDGAR LEBEL INC.1362-7674 BIJOUTERIE LEVER DU SOLEIL LTEE.et sa version anglaise SUNRISE JEWELLERY LTD.1371-8846 8, rue de la Cour.06 02 75 Rivière-du-Loup.880, Jean-Talon ouest, Montréal.14 03 75 Les EboulemenU.10 03 75 Drummondville.17 02 75 Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud.6, rue St-André, Québec.5950, rue Christophe-Colomb, Montréal.27 09 06 BIJOUTERIE RAYNALD SIMARD INC.1362-1586 BOHEMIER ET DORE INC.1362-5231 BOITE DE CAMION SAG U EN A Y LTEE.1362-3822 BOULANGERIE BERUBE LTEE.1362-5207 LA BOUTIQUE FRIZON LTEE.1362-4309 Pierrefonds.24 857, rue Ste-Hélène, Longueuil.10 Percé.26 900, 9e Avenue, Charny.18 318, rue Fleury ouest, Montréal.07 49, rue Child, Coaticook.07 1497, Elizabeth, Chomedey, Laval.27 340, D'Aiguillon, Québec.04 Ferme-Neuve.20 996, Lavoie.Chicoutimi.13 Forestville.oi Terrebonne.17 BOUTIQUE MONSAK INC.1371-5792 3040, chemin St-Louis, bureau 601, Sainte-Foy.04 BOUTIQUE NICODEME INC.1217, avenue Rousseau, Sillery.24 1361-9904 02 75 04 75 03 76 01 76 03 76 02 76 02 75 03 75 04 75 03 76 03 76 03 76 03 76 04 75 03 76 03 76 02 75 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1975.107' année, n° 19 3711 Nom / Name BOUTIQUE DE PLANTES MERE NATURE INC.et sa version anglaise MOTHER NATURE PLANT BOUTIQUE INC.1371-7814 BRASSERIE AU FESTIN INC.1371-7558 BRASSERIE LE CHARLOT DE SEPT-ILES INC.1362-7153 JEAN-DENIS BRODEUR.1371-5651 BENOIT BROUILLETTE INC.1371-9257 LES BRULEURS R.MONGEON INC.et sa version anglaise Jî.MONGEON OIL BURNERS INC.1371-9190 SYLVESTRE BRUNO INC.1371-8747 BUROFIL LTEE.1362-3954 LES CADEAUX COMMEMORATIFS PRESIDENT INC.et sa version anglaise PRESIDENT MEMORIAL GIFTS INC.1362-2709 RAYMOND CADIEUX INC.1371-9448 CAMERATRON INC.1362-0703 CARFIDEX INC.1371-5164 VIATEUR CARON INC.1361-8632 CARROSSERIE D'AUTO A & G.EDNA INC.et sa version anglaise EDNA.A & G AUTO BODY INC.1361-3286 CARROSSERIE D'AUTO G.LECLAIR INC.et sa version anglaise G.LECLAIR AUTO BODY INC.1371-6279 CARROSSERIE MONT BRUNO INC.1371-4605 CENTRE COMMERCIAL, INDUSTRIEL & SPORTIF MONT BLEU INC.1362-9456 CENTRE ELECTRONIQUE RICHARD INC.1371-5222 CENTRE DE L'ESTHETIQUE DE L'AUTOMOBILE DE LAVAL INC.1371-6345 CENTRE MEDICAL DE L'ANNONCIATION INC.1371-2781 Incorporation Siège social / Head Office Date Montréal.19 03 75 3290, rue Fabreville, Laval.17 03 75 685.rue Humphrey, Sept-Iles.02 04 75 690, rue Ste-Anne, Saint-Hyacinthe.03 03 75 179, Trahan, Saint-Jean.01 04 75 10603, rue Péloquin, Montréal.02 04 75 271, Duvernay, Beloeil.27 03 75 Acton-Vale.02 04 75 600, avenue Laurier, bureau 201, 11 03 75 Québec.Mascouche.02 04 75 3480, McCartney, app.102, Sainte- 27 02 75 Foy.5900, boulevard Léger, Montréal- 27 02 75 Nord.20, boulevard Taché ouest.Mont- 18 02 75 magny.95, Mont-Vernon, Saint-Pierre.20 01 75 Montréal.06 03 75 1227, boulevard Laurier, Saint-Bruno.24 02 75 63, rue Hôtel-de-Ville, Hull.16 04 75 Beloeil.28 02 76 195, rue du Parc, Laval-des-Rapides, 07 03 75 Laval.L'Annonciation.07 02 75 3712 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1976, Vol.107, No.19 Nom / Name CENTRE DE MOTOCYCLETTES KAWASAKI (LAVAL) LIMITEE 1371-1684 CENTRE DE RENOVATION STE-JULIENNE INC.1362-2881 CHARCUTERIE LA FRINGALE INC.1371-8937 E.CHARRIER INC.1362-1321 CHAUSSURES JOYCE ET LUC INC.1371-6154 CHEMISES WILLY K.LTEE.et sa version anglaise WILLY K.SHIRTS LTD.1362-1842 N.A G.CHOQUETTE INC.1362-1313 LES CINEMAS OMEGA LTEE.et sa version anglaise OMEGA CINEMA LTD.1362-1057 CINEMAS PLUS INC.1371-9232 CLINIQUE MEDICALE MADAME INC.1362-4523 CODISTAL LTEE.1362-3913 CODYFORT LTEE.1362-8771 COFFRAGES SIMBEC INC.et sa version anglaise SIMBEC FORMS INC.1371-7947 COGESAD INC.1362-2733 COMOVE LIMITEE.1362-0851 LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION J.T.B.INC.1371-6014 CONSTRUCTION AGENDA INC.1362-3103 CONSTRUCTION ALYRE TANGUAY INC.et sa version anglaise ALYRE TANGUAY CONSTRUCTION INC.1371-7269 LES CONSTRUCTIONS B.ET P.GAGNON LTEE.et sa version anglaise B.AND P.GAGNON CONSTRUCTION LTD.1361-1389 LES CONSTRUCTIONS COURVAL INC.et sa version anglaise COURVAL CONSTRUCTION INC.1362-2303 Incorporation Siège social / Head Office Date 335, boulevard Labelle, Chomedey, 30 01 76 Laval.Sainte-Julienne.07 03 75 Terrebonne.27 03 75 Saint-Ambroise-de-Kildare.27 02 75 615, Dorchester ouest, bureau 1010, 06 03 75 Montréal.9600, boulevard St-Laurent, Montréal.05 03 75 8080, boulevard Métropolitain est, 27 02 75 Montréal.455, rue Michel-Jasmin, Dorval.03 03 75 4015, boulevard St-Laurent, Montréal.01 04 75 430, rue Sherbrooke est, Montréal.19 03 75 1541.rue des Pins, Dolbeau.13 03 76 Dolbeau.21 04 75 3325, rue Christiane, Fabreville, Laval.20 03 75 Drummondville.11 03 75 Québec.26 02 75 861, rue Queen.Saint-Lambert.04 03 75 7.rue St-Michel, Chomedey, Laval.11 03 76 1660, Soucy, Saint^Hubert.14 03 76 Partie ouest, Hull.09 01 75 Saint-Zéphirin.06 03 75 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1976.107' année, n\" 19 3713 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date CONSTRUCTION GABIAN LTEE.et sa version anglaise GABIAN CONSTRUCTION LTD.1371-8887 CONSTRUCTION GASTON FAUTEUX INC.1362-2360 LES CONSTRUCTIONS JOUTEL INC.et sa version anglaise JOUTEL CONSTRUCTION INC.1371-5503 LES CONSTRUCTIONS LECUYER ET SURPRENANT INC.1362-1982 CONSTRUCTION MARCEL CROTEAU INC.1361-6081 CONSTRUCTION MARIVAL INC- et sa version anglaise MARIVAL CONSTRUCTION INC.1371-5032 CONSTRUCTIONS MAURICE ET GUY INC.1371-7335 CONSTRUCTION METALLIQUE G.B.I.LTEE 1371-7111 CONSTRUCTION TIDAN INC.et sa version anglaise TIDAN CONSTRUCTION INC.1371-5388 CONSTRUCTION VINTI INC.et sa version anglaise VINTI CONSTRUCTION INC.1371-6907 CONSTRUCTION VISCONTI INC.et sa version anglaise VISCONTI CONSTRUCTION INC.1362-5157 COR-LOU INC.1362-2295 ARMAND COUTURE & FILS INC.1362-4804 CREATIONS DIAMAYAN INC.1371-4340 CUIR RICHELIEU LTEE.et sa version anglaise RICHELIEU LEATHER LTD.1371-6568 DEPANNAGE DE ROULOTTES DE SHAWBRIDGE INC.1361-6297 DEPOUSSIEREURS ROUSSEAU INC.et sa version anglaise ROUSSEAU DUST COLLECTING SYSTEMS INC.1371-0033 DESMARAIS & GAUTHIER INC.1371-4282 9390, boulevard Viau, Saint-Léonard.27 03 75 Deauville.06 03 75 91.De Vimy, Ile-Jésus, Laval.28 02 75 37, rang St-Jean, Saint-Patrice-de-Slierrington.04 03 75 Granby.03 04 75 24 02 75 2200, rue Ste-Çatherine est, bureau 102, Montréal.Saint-Eustache.15 04 75 1255, rue University, Montréal.13 03 75 1480, Rockland, Mont-Royal.27 02 75 15, Cartier, Pointe-Claire.12 03 76 Dollard-des-Ormeaux.18 03 75 Laval.06 03 76 347, rue St-Ephrem, Chicoutimi-Nord 19 03 75 59, Place de Chatelet, Laval.21 02 75 Montréal.10 03 75 Route 117, Shawbridge.05 02 75 300, Canal Bank, Saint-Pierre.17 01 75 1633, boulevard Henri-Bourassa est, 21 02 75 Montréal.LUCIEN DESROCHERS INC.1362-4721 3535, rue Papineau, app.805, Montréal.18 03 75 3714 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107.A'o.19 Nom / Name.LES DICTIONNAIRES ROBERT LTEE.1361-9739 DIFFUSION AUDIO-VISUELLE MARTIN INC.1371-5461 DISTRIBUTION BOULIER INC.1372-0917 LES DISTRIBUTIONS M.C.D.INC.et sa version anglaise M.C.D.DISTRIBUTORS INC.1362-5942 DOMAINE CITE FUTURISTE INC.1371-1650 DONRAT INC.1371-6360 DUFOUR.PAPINEAU ET SARRAZIN INC.1361-9291 ECOLE DE MUSIQUE PAUL INC.1362-2899 ECONOFAR INC.1371-5693 EDIFICE F.GUILLEMETTE LTEE.1362-2154 LES EDITIONS MARTELL LTEE.1371-5974 YVON EMOND INC.1361-1603 LES ENDUITS BINCLO INC.et sa version anglaise BINCLO COVERING INC.1362-7054 ENTREPRENEURS PEINTRES LEVESQUE & CHEVALIER INC.1362-2105 LES ENTREPRISES ALCIDE SAUVE INC.1362-8375 ENTREPRISES BON CHOIX INC.1362-7583 LES ENTREPRISES ELECTRIQUES C.G.INC.et sa version anglaise C.G.ELECTRIC ENTERPRISES INC.1371-4175 LES ENTREPRISES FAROUK MADY INC.1359-7455 LES ENTREPRISES D'HOTELLERIE HOUBI INC.1361-5364 LES ENTREPRISES JACQUES LEMAY INC.1371-7954 LES ENTREPRISES L.S.N.INC.1362-5306 LES ENTREPRISES LEONARD DAVIS INC.1362-8581 Incorporation Siège social / Head Office Date 297, rue Benjamin-Hudon, Saint- 25 02 75 Laurent.Montréal.28 02 75 611, 1ère Avenue, Asbestos.15 04 75 60, rue St-Jacques, bureau 901, 25 03 75 Montréal.Montréal.30 01 75 6510, Bombardier, Saint-Léonard.07 03 75 Ferme-Neuve.20 02 75 3462, boulevard Dagenais.Fabreville, 07 03 75 Laval.7142, boulevard Taschereau, Brossard 05 03 75 466, rue de la Couronne, bureau 200, 06 03 75 Québec.615, Dorchester ouest, bureau 1010.05 03 75 Montréal.100, rue Principale, East-Broughton 08 01 75 Station.330, rue Brignon, Granby.01 04 75 2080, des Intendants, Québec.07 03 76 336, Graqnde-Côte, Bois-Briand.11 04 75 276, rue Scott est.Aima.03 04 75 1623.Chopin, Vimont, Laval.21 02 76 Cowansville.22 01 76 950, rue Royale, Trois-Rivières.31 01 75 1115, Sherbrooke ouest, Montréal.20 03 76 Sherbrooke.20 03 75 Stanstead.j j GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année.n° 19 3715 Nom/ Name LES ENTREPRISES PAUL-EMILE LETENDRE LTEE.1371-7566 ENTREPRISES ST-JANVIER (1975) LTEE.1362-1838 LES ENTREPRISES STOMAR INC.1361-5901 LES ENTREPRISES TONAN INC.1362-4416 EPICERIE CE.GAGNON & FILS LTEE.1360-4152 EQUIPEMENT HICKSON INC.1360-6793 EQUIPEMENT PRECIBEC INC.1371-5818 EQUIPEMENTS SANI-COM LTEE.1362-1016 EQUIPEMENTS SELECT INC.et sa version anglaise SELECT EQUIPMENT INC.1362-8334 LES ERECTIONS S.DUMAIS INC.1371-3656 EVALUATION ET CONSTRUCTION CANADIENNE J.B.J.INC.1362-1420 EXCAVATION N.Y.INC.1363-0397 EXCAVATION PAPINEAU & FRERES INC.1371-7830 EXCAVATION R.BOIVIN LTEE.et sa version anglaise R.BOIVIN EXCAVATION LTD.1371-9042 L'EXPRESS BOGOTA S.A.INC.et sa version anglaise BOGOTA EXPRESS S.A.INC.1371-7202 MICHEL FABIEN INC.1372-0164 FALBALAS DE PARIS INC.1372-0065 FENCLO LTEE.et sa version anglaise FENCLO LTD.1371-6295 FERMAGROUPE SINAI INC.1362-4135 FERMES NEVERETT INC.and its English version NEVERETT FARMS INC.1361-4961 LES FERMES P.& A.LTEE.et sa version anglaise P.ci A.FARMS LTD.1371-6535 Incorporation Siège social / Head Office Date Saint-David.18 03 75 190, rue Alarie, Saint-Janvier.03 03 75 12,000 boulevard Henri-Bourassa est, 04 02 75 Montréal 1, route Trans-Canada ouest, Lévis.17 03 75 640, rue Réal, La Tuque.26 11 74 1595, St-Hubert, Montréal.09 12 74 3863, Lesage, Verdun.04 03 75 Laval.26 02 75 117, de la Chaudière, Saint-Nicolas.10 04 75 2455, boulevard De Blois, 17 02 75 Duvernay, Laval.Saint-Emile.28 02 75 Pierreville.25 04 75 Sainte-Brigide.19 03 75 Saint-Jovite.01 04 75 1440, rue Towers, bureau 102, 14 03 75 Montréal.Montréal.09 04 75 169, rue Jarry est, Montréal.08 04 75 2907, boulevard Dagenais, Fabreville.06 03 75 Laval.Saint-Gédéon.14 03 76 Huntington.29 01 75 4, Carré Westmount, Westmount.10 03 75 3716 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Nom / Name Incorporation Siège social / Head office Date SainHUmi.24 01 75 Dorion.24 03 75 8888 rue Sherbrooke est, 21 03 75 Montréal.1530, Curé-Labelle, Laval.02 04 75 Longueuil.27 01 75 1270, St-Grégoire, Montréal.06 02 75 3210, avenue Forest Hill, app.1104, 28 04 75 Montréal.Québec.07 04 75 615, Dorchester ouest, bureau 1010, 07 03 75 Montréal.10, rue St-Jacques, bureau 909, 13 02 75 Montréal.Rimouski.10 04 76 103, Montée du Moulin, Laval.04 03 75 FINANCE M.P.INC.1360-7833 FLEMAR INC.1362-6189 CLAUDE FONTAINE INC.1362-0232 FOURNITURES INDUSTRIELLES DE LONGUEUIL LTEE.et sa version anglaise LONGUEUIL INDUSTRIAL SUPPLIES LTD.1371-9489 GARAGE ORLEANS INC.1371-1148 GARAGE TOURAINE LTEE et sa version anglaise TOURAINE GARAGE LTD.1361-6453 GUY GAUTHIER INC.1363-0991 GERICO INC.1362-0026 GESTION ARBALETE INC.1371-6162 GESTION G.I.L.LTEE 1361-7667 GESTION INTER-RIVES INC.1362-2329 GESTION RINES INC.et sa version anglaise RINES HOLDINGS INC.1371-5701 LES HABITATIONS DAVID W.FIELD INC.et sa version anglaise DAVID 11'.FIELD HOMES INC.1371-6899 LES HABITATIONS K.L.M.INC.1362-3962 LES HABITATIONS MONT SUN VALLEY INC.et sa version anglaise MOUNT SUN VALLEY HOMES INC.1371-7962 LES HUILES VI-TREM LTEE.1362-4283 J.HURLEY CANADA INC.1371-4795 LA HUTTE DU STEREO R.B.S.INC.et sa version anglaise R.B.S.STEREO HUT INC.1371-6287 LES IMMEUBLES CAMAGA INC.1361-7768 1117, rue Ste-Catherine ouest, bureau 606, Montréal 12 03 75 LES IMMEUBLES DESCALAFOR INC.1362-5785 362, boulevard Maloney est, 13 03 75 Gatineau.Mont-Suisse, Saint-Sauveur.20 03 75 150, Témiscouata, Rivièrc-du-Loup.17 03 76 Montréal.25 02 76 2720, Bernini-Crescent, Brossard.06 03 75 173, rue Commerciale, Cabano.12 02 75 540, 1ère Avenue, Québec.24 03 75 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3717 Nom / Name IMPORTATION JOHN GARTNER INC.et sa version anglaise JOHN GARTNER IM PORT INC.1362-8482 IMPORT-EXPORT B.T.M.INC.et sa version anglaise B.T.M.IMPORT-EXPORT INC.1371-2062 LES INDUSTRIES DEAUVILLE LTEE.et sa version anglaise DEAUVILLE INDUSTRIES LTD.1361-8137 LES INDUSTRIES THERMIK INC.et sa version anglaise THERMIK INDUSTRIES INC.1360-7130 LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES D.G.INC.1362-2766 LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES GAGNE & FILS INC.1363-0306 INSTALLATION R.A.INC.1362-4788 INVESTISSEMENTS BOGRAVIS INC.et sa version anglaise BOGRAVIS INVESTMENTS INC.1371-3300 LES INVESTISSEMENTS RIVIERE VERTE LTEE.et sa version anglaise GREEN RIVER INVESTMENTS LTD.1361-6917 DAVID ISRAEL ET ASSOCIES INC.et sa version anglaise DAVID ISRAEL AND ASSOCIATES INC.1362-4465 JARDIN NATUREL THEOPHILE INC.1371-7780 LES JARDINS STE-ROSE INC.1371-7343 JARMICY INC.1371-9281 JOURNAL MONDE DE LA DANSE INC.1370-8474 KARIMEX LTEE.et sa version anglaise KARIMEX LTD.1371-6808 LABORATOIRE G.B.INC.1371-7152 LABORATOIRE D'OPTIQUE ST-FRANCOIS D'ASSISE INC.1361-9515 LABORATOIRE D'OPTIQUE ST-VALLIER INC.1361-9960 JEAN-PAUL LACROIX INC.1371-7756 -., .Incorporation Siège social / Head Office Date Montréal.10 04 75 3, Place Ville-Marie, bureau 316, 31 01 75 Montréal.Deauville.14 02 75 1015, rue Riel, Lavai.10 12 74 Nicolet.10 03 75 Jonquière.22 04 76 Québec.19 03 75 Montréal.14 02 75 1440, rue Ste-Catherine ouest, 11 02 75 bureau 310, Montréal.Montréal.17 03 75 Rang numéro 6, Saint-Théophile.19 03 75 Laval.14 03 75 225, rue Notre-Dame ouest, Montréal.02 04 75 68, rue Cartier, bureau 108, Laval-des- 30 12 74 Rapides, Laval.Montréal.il 03 75 4605, rue Ste-Catherine est, Montréal.13 03 75 1680,1ère Avenue, bureau 202, Québec.21 02 76 446, rue St-Vallier ouest, Québec.25 02 75 2937, avenue Lacombe.Montréal.19 03 76 3718 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Nom / Name PAUL-EMILE LEFEBVRE INC.1362-7377 LEMERCIER & TROY INC.1362-0349 ANTOINE LHERMIE INC.1371-9760 LOCATERM LTEE.1369-2595 LOCATION D.D.LIMITEE.et sa version anglaise D.D.LOCATION LIMITED 1371-8382 LOCATION J.M.INC.1362-5769 GEORGES LORRAIN, PAYSAGISTE.INC.1371-7939 MARCHE BEAUNAYO INC.1362-6171 MARCHE E.DUFRESNE INC.1362-3228 MATERIAUX ACOUSTIQUES ROSEMONT INC.1360-2297 PLACIDE MATHIEU & FILS INC.1371-9844 MERCERIE CM.INC.1371-6238 METAL GALVANISE GASPESIE.1362-0307 BERNARD MONASTESSE INC.1371-8739 RICHARD NOLET, ELECTRICIEN INC.1371-5784 OXYGENE MONTOX INC.et sa version anglaise MONTOX OXYGEN INC.1371-8581 R.PERREAULT ET ASSOCIES INC.1371-9034 PIECES DE MOTEUR SIOUX INC.et sa version anglaise SIOUX MOTOR SUPPLY INC.1371-9992 LES PISCINES BEFOR LTEE.et sa version anglaise BEFOR SWIMMING POOLS LTD.1371-6584 LES PLACEMENTS ACADOUZE INC.1361-7519 LES PLACEMENTS B.L.R.INC.1361-8053 LES PLACEMENTS BEAUX-FRERES LTEE.1360-9276 Incorporation ! social / Head Office Date 348.rue Principale.Saint-Alban.07 04 75 Montréal.25 02 75 1455, rue Sherbrooke ouest, 07 04 75 bureau 1206-C, Montréal.239-1 le Avenue, Deux-Montagnes.08 08 74 5645, Grande-Allée, bureau 10, Bros- 24 03 75 sard.279, rue St-Jacques, Saint-Raymond.24 03 75 Lesage.20 03 75 3107, rue Lacombe, Montréal.24 03 75 4200, rue Ste-Catherine est.Montréal.12 03 75 4288, De La Roche, Montréal.02 04 75 290, rue Brodeur, Beloeil.07 04 75 229, Côte-Vertu, Saint-Laurent.06 03 76 Gaspé.24 02 75 1695.de Salaberry.Montréal.27 03 75 1011, rue St-Jean, Chambly.07 04 76 4890.5e Avenue, Rosemont.26 03 75 1030, Cherrier, bureau 104, Montréal.01 04 75 4690, rue de Bullion, Montréal.08 04 75 1030, boulevard Curé-Poirier ouest, 10 03 76 Longueuil.Sept-Iles.io 03 76 204, Des Tilleuls, Rimouski.14 q2 75 Sept-IIes.27 02 75 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3719 Nom I Name Siège social / Head Office Incorporation Date PLACEMENTS BOMIRE INC.1362-2998 LES PLACEMENTS CONDOR INC.1362-6247 PLACEMENTS DENLAB INC.et sa version anglaise DENLAB INVESTMENTS INC.1362-4879 LES PLACEMENTS G.A.T.INC.et sa version anglaise G.A.T.HOLDING INC.1362-8599 LES PLACEMENTS GERMARICH INC.et sa version anglaise GERMARICH INVESTMENTS INC.1362-5421 LES PLACEMENTS M.C.C.INC.1362-8391 LES PLACEMENTS SIXO INC.1362-7856 PLASTOCAP INC.1371-3813 PLOMBERIE ET CHAUFFAGE CARRIERE INC.et sa version anglaise CARRIERE PLUMBING AND HEATING INC.1371-1205 NELSON POTVIN INC.1362-6379 PRECIMECA LTEE.et sa version anglaise PRECIMECA LTD.1371-8374 PRESSE DU VILLAGE INC.et sa version anglaise VILLAGE PRESS INC.1371-7509 PRODUCTIONS PARAPLUIE LTEE.et sa version anglaise UMBRELLA PRODUCTIONS LTD.1371-7236 PRODUITS FIBRE D'OR INC.1362-7567 PROVALITE.INC.1371-6832 PUBLINORD INC.1361-7642 REMBOURRAGE ALI INC.1362-2212 RENOVATIONS D'IMMEUBLES S.M.LTEE.et sa version anglaise S.M.PROPERTY RENOVATION LTD.1371-5941 RESTAURANT A LA BONNE SAVEUR INC.1371-2658 158, boulevard du Pont, Saint-Nicolas.10 03 75 171, rue Frontenac.Sherbrooke.26 03 75 33, rue Blainville ouest, Sainte- 19 03 75 Thérèse.2290, boulevard Deblois, Duvernay, 15 04 75 Laval.255, rue St-Jacques ouest, Montréal.21 03 75 Sainte-Foy.1442, boulevard Walberg, Dolbeau.Saint-Damien.Hudson.Val-d'Or.Châteauguay.Hudson.11 04 75 10 04 75 19 02 75 27 01 75 27 03 76 24 03 76 17 03 75 1425, rue de la Montagne, Montréal .14 03 75 Victariaville.5338, rue St-Urbain, Montréal.Sept-Iles.Greenfield Park.115, rue d'Avignon, Dollard-des-Ormeaux.6595, chemin de la Côte St-Luc, bureau 706, Montréal.01 04 76 11 03 75 13 02 76 05 03 76 05 03 75 07 02 76 3720 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19___ Nom / Name RESTAURANT ANDRE LEGARE INC.1370-1180 RESTAURANT J.E.D.INC.1362-4002 RESTAURANT JEAN-CLAUDE PAUL INC.1371-9208 RESTAURANT LA BRIOCHE INC.1362-9233 RESTAURANT LA DEVINIERE INC.1371-3995 RESTAURANT LAGUNE INC.and its English version LAGUNA RESTAURANT INC.1371-1668 RESTAURANT LA JOCONDE INC.1363-0322 RESTAURANT LEONARDO DU CARRE PHILLIPS LTEE.1371-9547 RESTAURANT RIVE NORD INC.1371-7053 REVETEMENT LA RETOUCHE INC.1361-1371 ROBCEL LTEE.et sa version anglaise ROBCEL LTD.1365-0247 JEAN ROBERGE ET ASSOCIES INC.1371-3383 ROUVAN INC.1362-3251 SALAISON ROLAND PARENT INC.1362-0406 LE SALON DE DECORATION J.P.L.INC.1371-8010 SALON DE FLEURS TAHITI INC.et sa version anglaise TAHITI FLOWERS SHOP INC.1371-5891 LES SCIES RICHELIEU INC.et sa version anglaise RICHELIEU SAWS INC.1369-6010 SERPUBLI INC.1371-8473 SERVICE DE CONTROLE PYROMETRIQUE DE MONTREAL INC.1362-3418 SERVICE DE MAINTENANCE JERRY INC.1362-0372 SERVICE DE PERCEPTION COMMERCIAL B.C.INC.1369-9004 SERVICE DE PERSONNEL J.L.INC.1362-8490 Incorporation Siège social / Head Office _ .Date 10716, Pie IX.Montréal.22 10 74 416, rue Gauthier, Farnham.14 03 76 Papineauville.01 04 76 Saint-Paul-d'Abbotsford.16 04 76 91, rue St-Laurent ouest, Longueuil.20 02 75 7630, boulevard Lacordaire, 30 01 75 8aint-Léonard.Magasin Paquet, Place Laurier.23 04 75 Sainte-Foy.1245, Carré Phillips, Montréal.02 04 75 100, rue Brien, Repentigny.13 03 76 1673, Italie, Val-Bélair.09 01 75 630, boulevard Dorchester ouest, 17 04 76 Montréal.296, rue St-Paul ouest, Montréal.14 02 76 88, rue Laval, Noranda.12 03 75 1194, rue Chambly, Marieville.25 02 76 103, rue Plateau Ouimet, Sainte-Rose, 20 03 76 Laval.Montréal.05 03 76 Sant-Roch-de-Richelieu.09 10 74 10340, Esplanade, Montréal.24 03 75 Montréal.13 03 75 Rimouski.25 02 76 71?J,a.Veven that \"RIGO PROPANE INC.wUl apply to the Minister of Financial Institutions Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Vaudreuil, April 7th, 1975.ftnano Bissonnette & Cadieux, lawyers, ousua-° Attorneys for the company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3737 MONTREAL ODD FELLOWS TEMPLE CORPORATION Avis est par les présentes donné que « MONTREAL ODD FELLOWS CORPORATION », une compagnie constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte» conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal (Québec), ce 23e jour d'avril 1975.Le secrétaire, 60807 Lockhart Taylor.TINKA JEWELLERY LTD.Avis est, par les présentes, donné que « TINKA JEWELLERY LTD.» constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la cité de Drummondville, province de Québec, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Daté à Drummondville, le 1 avril 1975.Le président, 60810-o Arnold Webber.MONTREAL ODD FELLOWS TEMPLE CORPORATION Notice is hereby given that \"MONTREAL ODD FELLOWS CORPORATION\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, P.Q., this 23rd day of April, 1975.Lockhart Taylor, 60807-o Secretary.TINKA JEWELLERY LTD.Notice is hereby given that \"TINKA JEWELLERY LTD.\" a corporation constituted under the Companies Act and having its head office in the City of Drummondville, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated at Drummondville, this 1st day of April, 1975.Arnold Webber, 60810-o President.Divers Compagnie WESTERN INTERNATIONAL EXPLORATIONS LTD.Avis est donné que l'actif de la compagnie sera distribué parmi les actionnaires, proportionnellement au montant des actions qu'ils détiennent dans la compagnie, quinze jours après la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le secrétaire, 60774-o A.L.Fosbrookk.TWENTY CENTURY EXPLORATIONS LTD.Avis est donné que l'actif de la compagnie sera distribué parmi les actionnaires, proportionnellement au montant des actions qu'ils détiennent dans la compagnie, quinze jours après la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le secrétaire, 60775 A.L.Fosbrooke.MALARTIC HYGRADE GOLD MINES (QUEBEC) LTD.Avis est donné que l'actif de la compagnie sera distribué parmi les actionnaires, proportionnellement au montant des actions qu'ils détiennent dans la compagnie, quinze jours après la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le secrétaire, 60776 A.L.Fosbrooke.Miscellaneous Company WESTERN INTERNATIONAL EXPLORATIONS LTD.Notice is given that the assets of the Company will be distributed amongst the shareholders proportionately to the amount of shares they hold in the company fifteen days after the publication of the present notice in the Québec Official Gazette.A.L.Fosbrooke, 60774-o Secretary.TWENTY CENTURY EXPLORATIONS LTD.Notice is given that the assets of the Company will be distributed amongst the shareholders proportionately to the amount of shares they hold in the company fifteen days after the publication of the present notice in the Québec Official Gazette.A.L.Fosbrooke, 60775-o Secretary.MALARTIC HYGRADE GOLD MINES (QUEBEC) LTD.Notice is given that the assets of the Company will be distributed amongst the shareholders proportionately to the amount of shares they hold in the company fifteen days after the publication of the present notice in the Québec Official Gazette.A.L.Fosbrooke, 60776-o Secretary. 3738 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Assurances FIREMAN'S FUND AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que « FIREMAN'S FUND AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY », enregistrée sous le numéro 773 a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 2689 qui l'autorise à compter du 1er juillet 1974 à effectuer dans la Province des contrats relatifs aux genres d'assurance suivants: Vie; Accident et Maladie.Le siège social de la compagnie est situé à 3333, rue California, San Francisco, Californie, États-Unis d'Amérique.La compagnie a nommé M.R.Langlois, Suite 925, Édifice Sun Life, Montréal, son procureur dans la Province.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 14 avril 1975.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province.Le surintendant des assurances, 60740-18-2-o Roger-A.Camaraire.CHRYSLER LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA CHRYSLER COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE DU CANADA Avis d'émùsion de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que « CHRYSLER LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA-CHRYSLER COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE DU CANADA », enregistrée sous le numéro 772 a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 2688 qui l'autorise à compter du 1er avril 1975 à effectuer dans la Province des contrats relatifs aux genres d'assurance suivants: Vie; Accident et Maladie, limités à l'assurance crédit collective seulement.Le siège social de la compagnie est situé à 797, chemin Don Mills, Don Mills, Ontario.La compagnie a nommé M.Michael Sheehan, 220 est, Grande-Allée, Québec, son procureur dans la Province.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 14 avril 1975.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province, Le surintendant des assurances, 60741-18-2-o Roger-A.Camaraire.Insurance FIREMAN'S FUND AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY Notice of issue of license and certificate of registration Notice is hereby given that \"FIREMAN'S FUND AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY\", registered under number 773, has obtained the license and certificate of registry number 2689, authorizing it, as from the 1st of July 1974 to undertake in the Province contracts of insurance in the following classes: Life; Accident and Sickness.The head office of the company is situated at 3333 California Street, San Francisco, California, United States of America.The company has appointed Mr.R.Langlois, Suite 925, Sun Life Building, Montreal, its attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 14th of April 1975.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger A.Camaraire, 60740-18-2-o Superintendent of Insurance.CHRYSLER LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA CHRYSLER COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE DU CANADA Notice of issue of license and certificate of registration Notice is hereby given that \"CHRYSLER LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA \u2014 CHRYSLER COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE DU CANADA\", registered under number 772, has obtained the license and certificate of registry number 2688, authorizing it, as from the 1st of April 1975, to undertake in the Province contracts of insurance in the following classes: Life, Accident and Sickness, restricted to Creditors Group insurance only.The head office of the company is situated at 797 Don Mills Road, Don Mills, Ontario.The company has appointed Mr.Michael Sheehan, 220 Grande-Allée East, Québec, its attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 14th of April 1975.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger A.Camaraire, 60741-18-2-o Superintendent of Insurance. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3739 Commission des transports du Québec Québec Transport Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu » (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.[I \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées, i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes, \u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regu- lation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). 3740 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1976, Vol.107, No.19 ii.au moms trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things- \u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(c) Verification of permits.(d) Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.(e) * Special permits.* In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.Catégorie Class Sous-catégories Sub-classes Codes Montréal Québec Couleurs Numéros de dossiers Colours File numbers Transport public Public transport Transport général General trucking Location Leasing Transport spécialisé Specialized transportation Voyageur MPV QPV Passenger Écolier MPE QPE Student Taxi MPT QPT Taxicab Camionnage régulier MCR QCR Begular trucking Camionnage spécialisé MCS QCS Specialized trucking Transport en vrac MCV QCV Bulk transportation Location ML QL Leasing Maritime MSM QSM Water Aérien MSA QSA Air Ferroviaire MSF QSF Real Rose Pink Rouge foncé Dark red Jaune orange Orange Orange brûlé Burnt orange Vert pâle Light green Vert foncé Dark green Bleu pâle Light blue Bleu foncé Dark blue Mauve If OHM Brun Brown M 000001 à M 002000 Q 000001 à Q 001000 M 100001 à M 103000 Q 100001 à Q 102000 M 200001 à M 210000 Q 200001 à Q 205000 M 300001 à M 303000 Q 300001 à Q 302000 M 400001 à M 402000 Q 40C001 à Q 401000 M 500001 à M 504000 Q 500001 à Q 503000 M 600001 à M 601000 Q 600001 à Q 600500 M 700001 à M 700500 Q 700001 à Q 700500 M 800001 à M 800500 Q 800001 à Q 800500 M 900001 à M 900500 Q 900001 à Q 900500 MPV \u2014 Montréal transport public \u2014 voyageurs / Montreal public transport \u2014 passengers QPV \u2014 Québec transport public \u2014 voyageurs / Québec public transport \u2014 passengers MPE \u2014 Montréal transport public \u2014 écoliers / Montreal publie transport \u2014 students QPE \u2014 Québec transport public \u2014 écoliers / Québec public transport \u2014 students MPT \u2014 Montréal transport public \u2014 taxi / Montreal publie transport \u2014 taxicab QPT \u2014 Québec transport public \u2014 taxi / Québec public transport \u2014 taxicab MCR \u2014 Montréal transport régulier \u2014 camionnage / Montreal regular transportation \u2014 trucking QCR \u2014 Québec transport régulier \u2014 camionnage / Québec regular transportation \u2014 trucking GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107\u2022 année, n° 19 3741 MCS \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 camionnage / Montreal specialized transportation \u2014 trucking QCS \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 camionnage / Québec specialized transportation \u2014 trucking MCV \u2014 Montréal transport en vrac \u2014 camionnage / Montreal bulk transportation \u2014 trucking QCV \u2014 Québec transport en vrac \u2014 camionnage / Québec bulk transportation \u2014 trucking ML \u2014 Montréal location / Montreal leasing QL \u2014 Québec location / Québec leasing MSM \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 maritime / Montreal specialized transportation \u2014 water QSM \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 maritime / Québec specialized transportation \u2014 water MSA \u2014 Montréal transport specialise \u2014 aérien / Montreal specialized transportation \u2014 air QSA \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 aérien / Québec specialized transportation \u2014 air MSF \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Montreal specialized transportation \u2014 rail QSF \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Québec specialized transportation \u2014 rail I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu »: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission: La Commission donne avis qu'elle entend décider des affaires suivantes, conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les quinze jours francs de la date de la présente publication.The Commission gives notice of its intention to settle the following proceedings in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of fifteen clear days following the date of this publication.Rôle Q-3535 22154-V-P-l M.T.TRANSPORT INC.375, Principale La Sarre (Que.) Rôle Q-3638 22364-V-P-l CONSTRUCTION DBM INC.Ville Dégelie (Témiscouata) (Que.) Rôle Q-3561 23782-V-P-l PERRON, VICTORIEN 2720, rue St-Georges Giffard Québec 5 (Que.) Rôle Q-3562 23217-V-P-l LE MARCHÉ JULES LIMITÉE 140, 12e Avenue Drummondville (Que.) Rôle Q-3563 21486-V-P-l GAGNON, JEAN-URBAIN a/s Restaurant Lévesque Enr.329, rue St-Paul Québec (Que.) Rôle Q-3564 19296-V-P-2 BEL-MONT TRANSIT INC.143, Hébert CP.82, Mont-Joli (Que.) G5H 3K8 60769-o Aux fins de décréter, conformément à l'article 2.48.2, que le permis no 22154-V sera annulé pour n'avoir pas fourni les documents exigibles et réclamés par la Commission par les lettres des 14 janvier, 10 février et 7 mars 1975.Aux fins de décréter, conformément a l'article 2.48.2 que le permis no 22364-V sera annulé pour n'avoir pas fourni les documents exigibles et réclamés par la Commission par les lettres des 14 janvier, 10 février et 7 mars 1976.Aux fins de réviser la décision QS-879, en statuant sur le cautionnement de l'opposante, Del Transport Limitée.Aux fins de révoquer la décision autorisant la délivrance du permis no 23217-V, détenu par Le Marché Jules Limitée, et ce, à sa demande.Aux fins de révoquer la décision autorisant la délivrance du permis no 21486-V, ce permis n'étant plus opéré.Aux fins de révoquer la décision autorisant la délivrance du permis du tiré connexe à la décision autorisant la délivrance du permis du tireur ci-après nommé, et vice-versa, au motif que Bel-Mont Service Enr.n'existe plus.Bel-Mont Service Enr., 22438-V (Viateur Bélanger) 143.rue Hébert Mont-Joli (Rimouski) (Que.) For the purpose of ordering, in conformity with section 2.48.2, that permit No.22164-V shall be cancelled for not having provided the documents exigible and requested by the Commission in its letters dated January 14, February 10 and March 7, 1976.For the purpose of ordering, in conformity with section 2.48.2, that permit No.22364-V shall be cancelled for not having provided the documents exigible and requested by the Commission in its letters dated January 14, February 10 and March 7, 1975.For the purpose of revising decision QS-879, by rendering a decision concerning the deposit of the opposing party, Del Transport Limitée.For the purpose of revoking the decision authorizing the issue of permit No.23217-V, held by Le Marché Jules Limitée, the foregoing at the latter's request.For the purpose of revoking the decision authorizing the issue of permit No.21486-V, said permit being no longer in operation.For the purpose of revoking the decision authorizing the issue of the carrier's permit related to the decision authorizing the issue of the permit of the haulaway operator hereinafter mentioned, and vice versa, on the ground that Bel-Mont Service Enr.no longer exists.Bel-Mont Service Enr.22438-V (Viateur Bélanger) 143 Hébert Street Mont-Joli, (Rimouski) P.Q. 3742 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu »: La Commission donne avis qu'elle entend décider des affaires suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.Rôle M-8145 M-205662-P-1 BISAILLON, PAUL-ÉMILE 431.boul.Paquette Mont-Laurier (Qu6.) I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission: The Commission gives notice of its intention to settle the following proceedings in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publication.Aux fins de corriger la décision MPT-687 de la cause MT-0187 en date du 17 juin 1974 pour qu'elle se lise Mont-Laurier 07-7640-VT et non Labelle 06-7607-SD.For the purpose of correcting decision MPT-687 rendered on June 17.1974, in case MT-0187.by substituting \"Mont-Laurier 07-7640-VT\" for \"Labelle 06-7607-SD\".Rôle M-8146 3634-A-B-l CORBE1L, PAUL 1848, rue St-Georges.Ville Lemoyne (Que.) Aux fins de régulariser sa décision numéro MS-1364 datée du 20 mars 1975, il y a lieu d'effectuer la remise du cautionnement et de corriger « sera valide le 1er février 1975 seulement » par « sera valide du 1er février 1975 jusqu'au 30 juin 1975 seulement.» In order to put into proper form the Commission's decision number MS-1364, rendered on March 20, 1975.it is necessary to order the reimbursement of the deposit and to correct the phrase \"shall be valid as from February 1st, 1975, only\" to read as follows: \"shall be valid from February 1st, 1975 to June 30, 1975 only\".Rôle M-8168 M-202407-P-1 M-202407-D-O01 PELLETIER, JEAN-BAPTISTE 164, St-Jean-Baptiste Coaticook (Que.) Aux fins d'annuler la décision MPT-592 de la cause MT-0092 en date du 14 juin 1974 vu le désistement du requérant.For the purpose of cancelling decision MPT-592 rendered on June 14, 1974, in case MT-0092, considering the applicant's withdrawal.Rôle M-8241 M-100-050-P-1-13 LA COMMISSION SCOLAIRE RÉGIONALE YAMASKA Requérante/Applicant REAL GODIN Ste-Hélène (Bagot) (Que.) Entrepreneur/Contractor « Aux fins d'annuler les conclusions de la décision MPE-148 » en date du 26 mars 1975 et de remplacer l'approbation du prix des contrats adjugés comme suit: Circuit no: J11.780 14,695 \"For the purpose of cancelling the conclusions of decision MPE-148, rendered on March 26, 1975, and to correct the approved prices of the contracts awarded to read as follows: Route No.: 5 Î11,780 7 14,695 Rôle M-8262 M-203377-P-1 M-203377-D-001 SI NETTE, ROBERT 431, boul.Paquette Mont-Laurier (Que.) Rôle M-8263 M-202825-P-1 M-202825-D-1 LAJEUNESSE, OVILA 431, boul.Paquette Mont-Laurier (Que.) Aux fins de corriger la décision MPT-688 de la cause MT-0188 en date du 17 juin 1974 pour qu'elle se lise Mont-Laurier 07-7640-VT et non Labelle 06-7606-SD.Aux fins de corriger la décision MPT-686 de la cause MT-0186 en date du 17 juin 1974 pour qu'elle se lise Mont-Laurier 07-7640-VT et non Labelle 06-7607-SD.For the purpose of correcting decision MPT-688 rendered on June 17, 1974, in case MT-0188, as follows: for \"Labelle 06-7606-SD\" please read: \"Mont-Laurier 07-7640-VT\".For the purpose of correcting decision MPT-686, rendered on June 17, 1974, in case MT-0186, as follows: for \"Labelle 06-7607-SD\" please read: \"Mont-Laurier 07-7640-VT\".Rôle M-8264 M-202902-P-1 M-202902-D-001 DEPEAULT, NAZAIRE Village St-Valérien, (Shefford) (Que.) J0H 2B0 Aux fins de corriger la décision MPT-974 de la cause MT-0474 en date du 19 juin 1974 pour qu'elle se lise St-Valérien-de-MUton 06-3939-CT et non St-Thomas-de-Joliette 06\u20145801\u2014P.Eor \"\"e P^POse of correcting decision MPT-974, rendered on June 19, 1974, in case MT-0474, as follows: for \"St-Thomas-de-Joliette 06-5801-P\" please read: \"St-Valérien-de-Milton 06-3939-CT\".Rôle M-8265 M-202443-P-1 M-202443-D-001 BÉRARD, MME ALFRED St-Fran çois-Xa vier Brompton (Que.) Aux fins de corriger la décision MPT-553 de la cause MT-0053 en date du 14 juin 1974 pour qu'elle se lise St-François-Xavier-de-Brompton 05-3512-P et non St-Francois-Xavier05-3501-CT.{Jor the purpose of correcting decision MPT-553 rendered on June 14, 1974, in case MT-0053, as follows: for \"St-Francois-Xavier 05-3501-CT\" please read: \"St-t rançois-Xavier-de-Brompton 05-3512-P. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3743 Rôle M-8266 M-202442-P-1 M-202442-D-001 MORIN, RÉGIS St-François-Xavier Brorapton (Que.) Rôle M-8267 M-205075-P-1 M-205075(D-001 KERR, ALBERT GEORCE 575, Collège Richmond (Que.) Rôle M-8268 4201-V-D-l-P-l 156-DYL HEALY BROS.LIMITED 1489 Wellington Montréal (Que.) mise en cause Rôle 8332 15111-V-P-3 COLOSSAL CARRIERS LIMITED 400, Wright St-Laurent 379 (Que.) Rôle M-8333 22793-V-P-l ALLARD, GUY 1053, rue Papineau Ville de Laval (Que.) Rôle M-8388 10374-V-P-l A-l MOVING & TRANSPORT LIMITED 10630, rue Balzac Montréal 406 (Que.) Rôle Q-3537 22152-V-P-l JEAN-PAUL & DENIS TREMBLAY LTÊE 1842, boul.St-Anicet Bagotville (Que.) Aux fins de corriger la décision MPT-552 de la cause MT-0052 en date du 14 juin 1974 pour qu'elle se lise St-François-Xavier-de-Brompton 05-3512-P et non St-François-Xavier 05-3501-CT.Aux fins suivantes: 1.D\"annuler la décision MPT-836 de la cause MT-0336 en date du 18 juin 1974 vu le désistement du requérant.2.De disposer du cautionnement.Aux fins de corriger la nature d'une requête de la compagnie mise en cause qui a été publiée dans la Gazelle officielle du Québec du 6 avril 1974, no 14, page 2644 sous le no de rôle M-1535 et pour laquelle une décision fut rendue en date du 11 juillet 1974 sous le no MCS-580, ML-350 et qui se lit comme suit: Classe : Transport restreint - service local - service de remorquage seulement -Service : Montréal et toutes les localités situées à une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite ville.Condition et restriction : Pour pouvoir donner le service précité, le détenteur devra utiliser les remorques-citernes appartenant à/et louées de Dominion Glass Co.Ltd.qui les aura immatriculées à la province, et lesquelles seront immatriculées à la Commission par Healy Bros.Limited, en vue pour ce dernier de pouvoir tirer lesdites citernes avec ses tracteurs dûment immatriculés à la province et à la Commission, pour donner le service indiqué pour le compte de Dominion Glass Co.Ltd.Ce service est sujet aux conditions qui s'appliquent habituellement à ce genre de service.De façon à remplacer les mots « remorques-citernes » apparaissant à la Condition & restriction » du service indiqué par le mot « remorques ».Aux fins de corriger la décision de la Commission no MCR-1649 du 4 mars 1975.en ajoutant au dispositif 1-0 de la décision le nom a Newark » après n Weehaken ».Aux fins de disposer du cautionnement de cinquante ($50) dollars effectué par le requérant, ce qui fut omis dans la décision MCR-1569 du 5 février 1975, cause M-3497, requête no 22793-V-D-l.Aux fins de corriger la décision de la Commission des transports MCS-966 du 21 janvier 1975, cause M-3429, afin de la rendre conforme à la demande dans la Gazelle officielle du Québec, no 43 du 26 octobre 1974, page 8036.Aux fins de vérifier l'exploitation du permis no 22152-V détenu par Jean-Paul & Denis Tremblay Ltée et, s'il y a lieu, de révoquer la décision du 3 juillet 1972 autorisant le service en vertu de l'ordonnance no 22152-V.For the purpose of correcting decision MPT-552 rendered on June 14, 1974, in case MT-0052.as follows:for\"St-François-Xavier 05-3501-CT\" please read: St-François-Xa-vier-de-Brompton 05-3512-P\".For the following purposes: 1.To cancel decision MPT-836 rendered on June 18, 1974, in case MT-0336, considering the applicant's withdrawal.2.To dispose of the deposit.For the purpose of correcting the nature of an application made by the Company mise en cause, which request was published on April 6.1974, in the Québec Official Gazette, No.14, on page 2644, under roll number M-1535.and regarding which a decision was rendered on July 11, 1974, under No.MCS-580, ML-350 The application reads as follows: Class: Restricted trucking - local service - haulaway service only -Service : Montreal and all localities situated within a distance of five (5) miles from the limits of said City.Condition and restriction: In order to provide the aforesaid service, the holder shall utilize the tank trailers belonging to/and rented from Dominion Glass Co.Ltd., which tank trailers shall be registered in the Province by said Company and with the Commission by Healy Bros Limited, so that the latter may haul said tanks its tractors, duly registered in the Province and with the Commission, to provide the service described, on behalf of Dominion Glass Co.Ltd.This service shall be subject to the conditions that usually apply to this type of service.In order to replace the words \"tank trailers\" which appear in the « Condition and rectriction\" of the service described, by the word \"trailers\".For the purpose of correcting decision No.MCR-1649 rendered by the Commission on March 4, 1975, by adding the name \"Newark\" after \"Weehaken\", in conclusion 1-0 of the decision.For the purpose of disposing of the fifty-dollar ($50) deposit made by the applicant: the Commission failed to do this in decision MCR-1669 rendered on February 5, 1975, in case M-3497, request No.22793-V-D-l.For the purpose of correcting decision MSC\u2014966, rendered by the Commission on January 21, 1975, in case M-3429, in order to make it conformable to the application published in the Quebec Official Gazelle, No.43, dated October 26, 1974, on page 8036.For the purpose of verifying the operation of permit No.22152-V, held by Jean-Paul & Denis Tremblay Ltée and, if need be, of revoking the decision rendered on July 3, 1972 authorizing the service by virtue of Order No.22152-V. 3744 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Rôle Q-3643 Q-201550-P-1 PAUL ROUSSEL 122, boul.Notre-Dame Pont-Rouge (Portneuf) (Que.) Rôle Q-3544 Q-200590-P-1 TARDIF & CÔTÉ 202.Lachance Beaupré (Montmorency) (Que.) Rôle Q-3545 Q-200441-P-1 ALBERT LAPOINTE Ste-Sabine (Bellechasse) (Que.) Rôle Q-3546 Q-201747-P-1 ROSARIO ALLARD CP.7.Matapédia (Que.) Rôle Q-3547 Q-201916-P-1 FLORI AN BERTRAND 11, 17e Rue Val St-Michel (Que.) Rôle Q-3648 Q-502999-P-001 GEORGES TREMBLAY 3024.boul.Ste-Geneviève Chicoutimi-Nord (Que.) Rôle Q-3560 13087-V-P-l-TF TRANSPORT VIEL LTÉE 718.rue Dumont Notre-Dame-du-Lac (Témiacouata) (Que.) Rôle Q-3636 3859-V-P-l CEORCES TREMBLAY 3094.boul.Ste-Geneviève Chicoutimi-Nord (Que.) 60769-o Aux fins de reviser la décision QPT-0863 datée du 19 juillet 1974, pour révoquer le permis de propriétaire de taxi à toutes fins que de droit, à la demande du détenteur.Aux fins de reviser la décision QPT-0487 datée du 12 juillet 1974, pour révoquer le permis de propriétaire de taxi à toutes fins que de droit, à la demande du détenteur.Aux fins de reviser la décision QPT-0300.en date du 9 juillet 1974, pour révoquer le permis de propriétaire de taxi à toutes fins que de droit, a la demande du détenteur.Aux fins de révoquer l'attestation Q-201747-D-1 du 23 janvier 1974, à la demande du détenteur.Aux fins de révoquer la décision QPT-71 datée du 7 juin 1974 autorisant en faveur du requérant-acquéreur, Louis-Philippe Rochet-te, la délivrance d'une attestation, vu le désistement du requérant-vendeur, M.Florian Bertrand.Aux fins de révoquer l'attestation numéro Q-502999-D-5, au motif que lors de la demande, le camion n'avait pas été immatriculé depuis 1971, et de considérer en même temps les demandes dans les causes numéros Q-3263 et Q-3S19.Aux fins de corriger la décision no QCR-991-TF du 8 avril 1976 on l'on airait dû mentionner: Lois renversés à Montréal : S1.00 cwt au lieu de Lots renversée à Montréal : $0.60 cwt Aux fine de: 1.vérifier le permis détenu par le détenteur en regard des services qu'il est autorisé à donner en vertu dudit permis par suite de son changement de domicile et de place d'affaires : 2.réviser, aux fins de la révoquer, la décision autorisant la délivrance du permis qui n'est plus conforme aux exigences de l'Ordonnance générale sur le camionnage.For the purpose of revising decision QPT-0863 rendered on July 19.I*7*;, .order to revoke the taxicab owner a permit at the holder's request, the foregoing, for all legal purposes.For the purpose of revising decision QPT-0487 rendered on July 12, 1974, in order to revoke the taxicab owner's permit at the holder's request, the foregoing, for all legal purposes.For the purpose of revising decision QPT-0300 rendered on July 9, 1974, in order to revoke the taxicab owner's permit at the holder's request, the foregoing, for all legal purposes.For the purpose of revoking certificate O-201747-D-1.dated January 23, 1974.at the holder's request.For the purpose of revoking decision QPT-71, rendered on June 7, 1974, authorizing the issue of a certificate in behalf of the applicant-purchaser, Louis-Philippe Ro-chette, considering the withdrawal of the applicant-vendor, Mr.Florian Bertrand.For the purpose of revoking certificate number Q-502999-D-5.on the ground that, at the time when application was made, the truck had not been registered since 1971; for the purpose of considering at the same time the applications made in cases numbers Q-3263 and Q-3619.For the purpose of correcting decision No.QCR-991-TF rendered on April 8, 1976.in which one should read: Loads discharged in Montreal: $1.00 cwt instead of : Loads discharged in Montreal: $0.60 cwt For the following purposes: 1.owing to the holder's having changed the address of his domicile and place of business, to verify the Litter's permit, as regards the services which he is authorized to provide by virtue of said permit; 2.to revise, for the purpose of revoking it, the decision authorizing the issue of said permit, which is no longer in conformity with the requirements of the General Order on Truoking.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes : La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.LI \u2014 Notice of submission of applications : The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.The applicant, owner of a truck registered in the Province of Québec since April 14, 1972, requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit.Contractor class, for Region No.10.Rôle M-6919 La requérante, propriétaire d'un camion M-505585-D-001 immatriculé au Québec depuis le 14 avril AURÉLIEN BOILY INC 1972, demande à la Commission des trans- mion -r- r- ports du Québec un permis de camionnage 1B3JO, rerrasse Goretti en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la Montréal (Que.) région no 10. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3745 Nouvelle publication remplaçant celle parue dans la Gazette officielle du Québec no 12, page 2521, rôle M-6919 et qui était erronée.Rôle M-7150 M-503245-D-001 PILOTTE, MARCEL 902, Anne-Lemovne Boucherville (Que.) Région 6 Entrepreneur Le requérant, détenteur de l'attestation M-503245-D-001, demande à la Commission des transports de transférer son attestation ou son permis de la région no 6 à la région no 10 avec changement d'adresse : 4002, rue Joffre Montréal (Que.) Nouvelle publication remplaçant celle parue dans la Gazette officielle du Québec no 13, page 2862, rôle M-7160 et qui était erronée.Rôle M-7879 M-505099-D-002 LES ENTREPRISES D'AUTRAIE INC.420, Bois D'Autraie Berthierville (Que.) Région 6 Entrepreneur Le requérant, qui possède l'attestation no M-505099-D-002 émise le 4 janvier 1974, pour opérer dans la région no 6, catégorie Entrepreneur, demande que cette attestation soit transférée dans la région no 5 à l'adresse suivante: 1161, rue Lindberg Sherbrooke (Sherbrooke) (Que.) Rôle M-8045 1222-V-D-l DESMARAIS, MICHEL 1142, rue Principale St-Thomas (Joliette) (Que.) Nouvelle clause: Le requérant s'adresse à la Commission des transports du Québec dans le but d'être autorisé à donner le service de transport suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - De St-Eustache à St-Thomas, Notre-Dame-de-Lourdes, Ste-Mélanie, St-Paul-de-Joliette, L'Assomption, Lavaltrie, Lanoraie et Berthier, pour le transport de chaux en vrac, pour le compte de Servicentre Harnois Inc.Rôle M-8047 196-V D-3 HOULE EXPRESS LIMITÉE 502, rueNotre-Dame St-Rémi-de-Napierville (Que.) Modification de la clause c: La requérante qui détient actuellement la clause c suivante: c) Transport général - longue distance -route restreinte - c) De St-Rémi, St-Michel, St-Isidore, St-Constant.Delson, Laprairie, à Montréal, et retour.désirerait que ladite clause c se lise dorénavant comme suit: c) Transport général - longue distance -route restreinte - c) De St-Rémi, St-Michel, St-Isidore, St-Constant, Delson, Laprairie, à Montréal, Mirabel et retour.Rôle M-8048 20681-V-D-l LA COMPAGNIE MAURICE & CLAUDE LTÉE 3055.boul.Queen Nord Sherbrooke (Que.) Modification: 1.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec d'effectuer le changement de son nom.ainsi que son siège social présentement situé à: Maurice A Claude Co.Ltée 222.rue Principale Windsor Mills (Que) pour se lire à l'avenir comme suit: La Compagnie Maurice A Claude Ltée 3055, boul.Queen nord Sherbrooke (Que.) 2.La partie requérante dont les clauses a et b se lisent comme suit: a) Transport restreint - service local -fardier - a) Windsor Mills et les localités situées sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite municipalité; New publication replacing the one which appeared in the Québec Official Gazette, No.12, on page 2521.Roll M-6919, and which was erroneous.Region 6 Contractor The applicant, holder of certificate M-503245-D-001.requests the Transport Commission to transfer his certificate or permit from Region No.6 to Region No.10, with a change of address : 4002 Joffre Street Montreal, P.Q.New publication replacing the one which appeared in the Québec Official Gazette No.13, on page 2862, Roll M-7150, and which was erroneous.Region 6 Contractor The applicant, which holds certificate No.M-505099-D-O02, issued on January 4, 1974, to operate in Region No.6, Contractor class, requests that such certificate be transferred to Region No.5 at the following address: 1161 Lindberg Street Sherbrooke (Sherbrooke) P.Q.New clause : The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following transport service: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From St-Eustache to St-Thomas, Notre-Dame-de-Lourdes, Ste-Mélanie, St-Paul-de-Joliette, L'Assomption, Lavaltrie, Lanoraie and Berthier, for the transport of lime in bulk, on behalf of Servicentre Harnois Inc.Modification to clause c: The applicant, which presently holds a permit wherein clause c reads as follows: (c) General trucking - long distance - restricted route - (c) From St-Rémi, St-Michel.St-Isidore.St-Constant.Delson, Laprairie to Montreal, and return.would wish said clause c to read henceforth as follows: (c) General trucking - long distance - restricted route - (c) From St-Rémi, St-Michel, St-Isidore, St-Constant, Delson, Laprairie, to Montreal, Mirabel and return.Modification: 1.The applicant requests the Québec Transport Commission to correct its name and the address of its head office which presently read as follows: Maurice A Claude Co Ltée 222 Principale Street Windsor Mills, P.Q.to read henceforth as follows: La Compagnie Maurice A Claude Ltée 3055 Queen North Boulevard Sherbrooke, P.Q.2.The applicant, holder of a permit in which clauses a and 6 read as follows: (a) Restricted trucking - local service -float - (a) Windsor Milts and the localities situated within a distance of 5 miles from the limits of said Municipality; 3746 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10.1975.Vol.107, No.19 Rôle M-8049 30004-D-85-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS.1434, Ste-Catherine.suite 404 Montréal (Que.) b) Transport restreint - longue distance -rayon - tardier - 6) De Windsor Mills à toutes les localités situées dans un rayon de 25 milles de ladite municipalité et retour.Dans les 2 cas.pour le transport par far-diers de machinerie et équipement d'entrepreneurs en travaux d'excavation, aqueduc, égouts et dont le déplacement à cause de leurs forme, dimensions, ou poids, requiert l'usage d'un matériel roulant spécial tel qu'un fardier, de même que les accessoires et matériaux dont le transport est nécessairement occasionné par le déplacement des objets susmentionnés.demande à la Commission des transports l'autorisation de déplacer le point d'origine des clauses a et 6 et étendre le service de la clause b à 50 milles.Lesdites clauses devraient se lire à l'avenir comme suit: a) Transport restreint - service local -fardier - a) Sherbrooke et les localités situées sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite municipalité; b) Transport restreint - longue distance -rayon - fardier - 6) De Sherbrooke à toutes les localités situées dans un rayon de 50 milles des limites de ladite municipalité et retour; Dans les 2 cas, pour le transport par far-diers de machinerie et équipement d'entrepreneurs en travaux d'excavation, aqueduc, égouts et dont le déplacement à cause de leurs forme, dimensions ou poids requiert l'usage d'un matériel roulant spécial tel qu'un fardier, de même que les accessoires et matériaux dont le transport est nécessairement occasionné par le déplacement des objets sus-mentionnés.La requérante demande que les modifications suivantes entrent en vigueur 45 jours après la date de la décision concernant cette requête.Thibeau Transport Limited, Pembroke (Ontario) : tarif spécial portant sur le service à contrat.B.T.Q.no 1335.1.Eddy Match Company Limited, Pembroke (Ontario) Chlorate de potassium (en poudre) Entre: Buckingham (Québec) Et: Pembroke (Ontario): 910 le cent livres; charge complète, minimum: 30,000 lb.Retour des tonneaux vides: 740 le cent livres; charge complète, minimum: 40,000 lb.Entre: Pembroke (Ontario) Et: Montréal (Québec): 1630 le cent livres, charge incomplète 2.Forest Valley Lumber Limited, Pembroke (Ontario) Bois brut et bois blanchi Entre: Pembroke (Ontario) Et: Montréal (Québec): 740 le cent livres; charge complète, minimum: 30,000 lb.3.National Grocers Co.Ltd., Pembroke (Ontario) Sucre Entre: Montréal (Québec) Et: Pembroke (Ontario): 770 le cent livres; charge incomplète, minimum: 30,000 lb.620 le cent livres; charge incomplète, minimum: 40,000 lb.Comprenant les marchandises suivantes: Ris 1090 le cent livres Epiceries 2070 le cent livres Fruits 2070 le cent livres (6) Restricted trucking - long distance -radius - float - \u201e .\u201e,:,;\u201e- (b) From Windsor Mills to all localities situated within a radius of 25 miles from the said Municipality and return._ In both cases, for the transport, by noats, of machinery and equipment used by excavation, water and sewer works contractors; the transport of which equipment, because of its shape, size or weight, requires the utilization of special rolling-stock such as floats, together with auxiliary parts and materials whose transport necessarily coincides with the moving of the aforementioned items.requests from the Transport Commission authorization to change the point of origin stipulated in clauses a and b and to extend the service authorized by clause b to a radius of 50 miles.The said clauses should read henceforth as follows: (a) Restricted trucking - local service -float - (a) Sherbrooke and the localities situated within a distance of 5 miles from the limits of said Municipality; (6) Restricted trucking - long distance -radius - float \u2014 (6) From Sherbrooke to all localities situated within a radius of 50 miles from the limits of said Municipality and return; In both cases, for the transport, by floats, of machinery and equipment used by excavation, water and sewer works contractors; the transport of which equipment, because of its shape, size or weight, requires the utilization of special rolling-stock such as floats, together with auxiliary parts and materials whose transport necessarily coincides with the moving of the aforementioned items.Request these modifications become effective 45 days following the date of decision on this application.Thibeau Transport Limited, Pembroke, Ontario: Special tariff covering contract service, T.B.Q.No.1335.1.Eddy Match Company Limited, Pembroke, Ontario Potassium chlorate (Powdered) From: Buckingham, Québec To: Pembroke, Ontario: 910 cwt.; TL, minimum: 30,000 lb.Return of empty drums: 740 cwt.; TL, minimum: 40,000 lb.From: Pembroke, Ontario To: Buckingham, Québec 1630 cwt.; LTL 2.Forest Valley Lumber Limited, Pembroke.Ontario Rough and dressed lumber From: Pembroke, Ontario To: Montreal, Québec: 740 cwt.; TL, minimum: 30,000 lb.3.National Grocers Co.Ltd., Pembroke, Ontario Sugar From: Montreal, Que.To: Pembroke, Ontario: 770 cwt.; TL, minimum : 30,000 lb.620 cwt.; TL, minimum: 40,000 lb.Included with above load: Rice 1090 cwt.Groceries 2070 cwt.Fruit 2070 cwt. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1975.107' année.n° 19 3747 Produits en conserve livrés jusqu'à notre camion et compris avec le chargement de sucre: 1090 le cent livres.Produits en conserve : Entre: Montréal (Québec) Et: Pembroke (Ontario): 1180 le cent livres; charge complète, minimum: 24,000 lb.1070 le cent livres; charge complète, minimum: 30,000 lb.4.Ottawa Valley Grain Products Limited, Pembroke (Ontario) Graines Entre: Pembroke (Ontario) Et: Montréal (Québec): 950 le cent livres; charge complète, minimum: 22,000 lb.Entre: Montréal (Québec) Et: Pembroke (Ontario) Concentrés: 860 le cent livres; charge complète, minimum : 22,000 lb.Engrais: 730 le cent livres; charge complète, minimum : 30,000 lb.Insecticides: 950 le cent livres; charge complète, minimum: 22,000 lb.Sels: 730 le cent livres; charge complète, minimum : 30,000 lb.5.Pembroke Salvage Co.Limited, Pembroke (Ontario) Entre Pembroke (Ontario) et Montréal (Québec).Ferraille : 730 le cent livres ; charge complète, minimum: 30.000 lb.Cuivre, laiton: 950 le cent livres; charge complète, minimum: 22,000 lb.Acier: 950 le cent livres; charge complète, minimum: 22,000 lb.6.Abitibi Containers Limited, Pembroke (Ontario) Entre: Pembroke (Ontario) Et: Montréal (Québec) Boites de carton gaufré, démontées: 980 le cent livres; charge complète, minimum 20,000 lb.Déchets de papier : 980 le cent livres ; charge complète, minimum : 20,000 lb.Entre: Montréal (Québec) Et: Pembroke (Ontario) Carton bois: 890 le cent livres; charge complète, minimum: 24,000 lb.7.Pleasant View Dairy Limited, Pembroke (Ontario) Entre: Montréal (Québec) Et: Pembroke (Ontario) Bouteilles de lait vides: 1410 le cent livres; charge complète, minimum: 22,000 lb.Entre: Pembroke (Ontario) Et: Montréal (Québec) Lait en poudre: 1840 le cent livres; charge complète, minimum: 10,0001b.Beurre: 1840 le cent livres; charge complète, minimum : 10,000 lb.8.Gilles Bros.& Co.Ltd., Braeside (Ontario).Bois brut ou blanchi Entre: Waltham (Québec) Et: Toronto (Ontario) : $217.99 le cent livres; minimum: 38,000 lb.Entre: Braeside (Ontario) Et: Québec, région iAi: conformément à la carte ci-jointe $163.20 Entre : Braeside (Ontario) Et: Québec, région « B »: conformément à la carte ci-jointe $223.85 Entre: Braeside (Ontario) Et: Québec, région c C »: conformément à la carte ci-jointe $245.50 Entre: Braeside (Ontario) Et: Québec, région n D »: conformément à la carte ci-jointe $303.26 Canned goods delivered to our truck and included with sugar load: 1090 cwt.Canned goods: From: Montreal, Québec To: Pembroke, Ontario: 1180 cwt.; TL.minimum: 24,000 lb.1070 cwt.; TL, minimum: 30,000 lb.4.Ottawa Valley Grain Products Limited, Pembroke.Ontario Seed grain From: Pembroke, Ontario To: Montreal, Québec: 950 cwt.; TL, minimum: 22,000 lb.From; Montreal, Québec To: Pembroke, Ontario Concentrates: 860 cwt.; TL, minimum: 22,000 lb.Fertilizers: 730 cwt.; TL, minimum: 30.000 lb.Insecticides: 950 cwt.; TL.minimum 22.000 lb.Salts: 730 cwt.; TL, minimum: 30,000 lb.5.Pembroke Salvage Co.Limited, Pembroke, Ontario Between: Pembroke, Ontario and Montreal, Québec.Scrap metal: 730 cwt.; TL, minimum: 30,000 lb.Copper, brass: 960 cwt.; TL, minimum: 22.000 lb.Steel: 950 cwt.; TL, minimum: 22,000 lb.6.Abitibi Containers Limited, Pembroke, Ontario From: Pembroke, Ontario To: Montreal, Québec Corrugated boxes, K.D.: 980 cwt.; TL.minimum: 20,000 lb.Scrap paper: 980 cwt.; TL, minimum: 20,000 lb.From: Montreal, Québec To: Pembroke, Ontario Wildpulpboard: 890 cwt.; TL, minimum: 24,000 lb.7.Pleasant View Dairy Limited, Pembroke, Ontario.From: Montreal, Québec To: Pembroke, Ontario Empty milk bottles: 1410 cwt.; TL, minimum: 22,000 lb.From : Pembroke, Ontario To: Montreal, Québec Powdered milk: 1840 cwt.; TL, minimum: 10,000 lb.Butter: 1840 cwt.; TL, minimum: 10,000 lb.8.Gilles Bros.& Co.Ltd., Braeside, Ontario Lumber, Rough or Dressed From: Waltham, Québec To: Toronto, Ontario: $217.99 cwt.; minimum: 38,000 lb.From: Braeside, Ontario To : Quebec Area « A » : as per attached map $163.20 From : Braeside, Ontario To : Québec Area « B » : as per attached map $223.86 From: Braeside, Ontario To: Québec Area « C o: as per attached map $245.60 From : Braeside, Ontario To: Québec Area ¦ D » : as per attached map $303.26 3748 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Entre : Breaside (Ontario) Et: Québec, région « E »: conformément à la carte ci-jointe $327.82 Entre: Braeside (Ontario) Et: Québec, région iFi: conformément à la carte ci-jointe $392.90 Entre Braeside et Québec: 36,000 lb, poids minimums des chargements transportés.9.The Steel Equipment Company Limited, Pembroke (Ontario) Ameublement de bureau, emballé ou non emballé.Entre: Pembroke (Ontario) Et: Montréal (Québec): 1630 le cent livres; charge complète, minimum: 24,000 lb.Rayonnage en acier Entre: Pembroke (Ontario) Et: Montréal (Québec): 144c le cent livres; charge complète, minimum: 30,000 lb.10.Cockburn & Archer Company Limited, Pembroke (Ontario) Entre: Montréal (Québec) Et: Pembroke (Ontario) Clous: 117é le cent livres; charge complète, minimum: 30,000 lb.850 le cent livres; charge complète, minimum: 40,000 lb.Revêtement pour toitures, en fer ou en acier: 1830 le cent livres; charge complète, minimum: 10,000 lb.Peinture: 1120 le cent livres; charge complète, minimum: 24,000 lb.Revêtement pour toitures, préparé: 850 le cent livres; charge complète, minimum: 40,000 lb.From: Braeside, Ontario ., To: Québec Area « E »: as per attached map $327.82 From: Braeside, Ontario , , To: Québec Area « F »: as per attached map $392.90 - ,, Minimum weights on Braeside to Quebec Loads 36,000 lb.9.The Steel Equipment Company Limited, Pembroke, Ontario Crated and uncrated office furniture.From: Pembroke, Ontario To: Montreal, Québec: 1630 cwt.; TL, minimum: 24,000 lb.Selving - Steel From: Pembroke, Ontario To: Montreal, Québec: 1440 cwt.; TL, minimum: 30,000 lb.10.Cockburn & Archer Company Limited, Pembroke, Ontario From: Montreal, Québec To: Pembroke, Ontario Nails: 1170 cwt, TL, minimum: 30,000 lb 850 cwt.TL, minimum: 40,000 lb.Roofing, iron or steel : 1830 cwt.TL, minimum: 10,000 lb.Paintsf 1120 cwt.TL, minimum: 24,000 lb.Roofing, prepared: 850 cwt.TL, minimum: 40,000 lb.Rôle M-8050 30004-D-84-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS.1434, Ste-Catherine, suite 404 Montréal (Que.) La requérante demande que ces modifications entrent en vigueur 45 jours après la date de la décision portant sur cette requête.Motorways (Ontario) Limited: Tarif spécial B.T.Q.no 1086 applicable aux services par contrat, Y participent: Glengarry Transport Ltd.Highland Transport Co.Ltd.Husband Transport Ltd.Kingsway Transports Ltd.Maislin Transport Ltd.Overrule Express Ltd.Smith Transport Co.Ltd.Taggart Service Ltd.Tarif indépendant couvrant les services par contrat 1.Canadian International Paper Co.Ltd., Gatineau (Québec).Papier-journal Entre: Gatineau (Québec) Et: Mississauga (Ontario) : 550 le cent livres; chargement complet, min.40,000 Toronto (Ontario) : 550 le cent livres; chargement complet, min.40,000 2.Canadian International Paper Co.Ltd., Gatineau (Québec) International Panelboard Ltd., Gatineau (Québec) Masonite Co.of Canada Ltd., Gatineau (Québec) Panneaux muraux Entre : Gatineau (Québec) Et: Hamilton (Ontario): 890 le cent livres; chargement complet, min.24,000 79e le cent livres : chargement complet, min.30,000 740 le cent livres: chargement complet, min.40,000 Request these modifications become effective 45 days following the date of decision on this application.Motorways (Ontario) Limited: Special contract tariff T.B.Q.No.1086 Concurred in by: Glengarry Transport Ltd.Highland Transport Co.Ltd.Husband Transport Ltd.Kingsway Transports Ltd.Maislin Transport Ltd.Overnite Express Ltd.Smith Transport Co.Ltd.Taggart Service Ltd.Independent action tariff covering contract service.1.Canadian International Paper Co.Ltd., Gatineau, Québec.Newsprint Paper From: Gatineau, Que.To: Mississauga, Ont.: 550 cwt.; TL, min.40,000 Toronto, Ont.550 cwt.; TL, min.40,000 2.Canadian International Paper Co.Ltd., Gatineau, Québec International Panelboard Ltd., Gatineau, Québec Masonite Co, of Canada Ltd., Gatineau, Québec Wallboard From: Gatineau, Québec To: Hamilton, Ont.: 890 cwt.; TL, min.24.000 790 cwt.; TL, Min.30,000 740 cwt.; TL, min.40,000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1975.107' année, n° 19 3749 Rôle M-8051 22406- V-D-l NESEL FAST FREIGHT INCORPORATED 2480 Lawrence Avenue E.Unit 7 Scarborough (Ontario) Au Québec:/In Québec: 8200, de l'Industrie Ville d'Anjou (Que.) Et: Toronto (Ontario): 760 le cent livres; chargement complet, min.24,000 670 le cent livres; chargement complet, min.30,000 620 le cent livres; chargement complet, min.40,000 3.Commercial Alcohols Ltd., Gatineau (Québec) Alcool en barils Entre: Gatineau (Québec) Et: Hamilton (Ontario): 850 le cent livres; chargement complet, min.35,000 Toronto (Ontario) : 610 le cent livres; chargement complet, min.35,000 4.Commercial Alcohols Ltd., Gatineau (Québec) Alcool en vrac dans des remorques-citerne Entre: Gatineau (Québec) Et: Des points situés en Ontario et desservis directement: 650 par mille, aller-retour.Modification de la clause b : La partie requérante, qui détient le permis 22406-V dont la clause b se lit comme suit: b) Transport restreint - longue distance -route restreinte - véhicules spéciaux - b) De la frontière Québec-Ontario (postes d'entrée: Hull, Pointe-Fortune et Rivière-Beaudette) à Montréal et toutes les localités situées dans un rayon de 125 milles des limites de ladite ville, à l'exception de Cowansville, Waterloo, Victoriaville, Arthabaska, Warwick, Princeville, Plessisville et Daveluyville, et retour, pour le transport de meubles neufs emballés et non emballés, de lampes, oreillers, de marchandises rembourrées comprenant literie, matelas et coussins, ainsi que de ressorts de meubles dans des fourgons de démanagement spécialement conçus, de type à châssis coudé (drop-frame), pour le compte des manufacturiers desdites marchandises, depuis des points situés dans la province d'Ontario, ou vers ces mêmes points, suivant autorisation.Restriction re/clause b: Le service sus-mentionné ne devra être effectué que conformément à une attestation complémentaire délivrée le 16 mai 1972 par l'Ontario Highway Transport Board.désire que ladite clause 6 se lise à l'avenir comme suit: b) Transport restreint - longue distance -route restreinte - véhicules spéciaux - 6) Depuis la frontière Québec-Ontario (postes d'entrée: Hull, Pointe-Fortune, Ri-vière-Beaudette, Judge, Cheminis) jusqu'à Montréal et aux localités situées dans un rayon de 125 milles des limites de ladite ville et retour, pour le transport de meubles neufs emballés ou non emballés, de lampes, oreillers, de marchandises rembourrées, de literie, matelas, coussins, ainsi que de ressorts de meubles et pièces composantes de meubles, dans des fourgons de déménagement spécialement conçus de type à châssis coudé (drop-frame), pour le compte des manufacturiers (ou de leur.-: représentants) ou des distributeurs desdites marchandises, depuis des points situés dans la province d'Ontario, ou vers ces mêmes points, suivant autorisation.Restriction re Clause b: Le service sus-mentionné ne devra être effectué que conformément à une attestation complémentaire délivrée le 4 février 1975 par l'Ontario Highway Transport Board.To: Toronto, Ont.: 760 cwt.; TL, min.24,000 670 cwt.; TL.min.30,000 620 cwt.; TL, min.40,000 3.Commercial Alcohols Ltd., Gatineau, Québec Alcohols, in drums.From: Gatineau.Québec To: Hamilton, Ont.: 850 cwt.; TL, min.35,000 Toronto, Ont.: 610 cwt.; TL, min.35,000 4.Commercial Alcohols Ltd., Gatineau, Québec Alcohols, in bulk, in tank trailers.From: Gatineau, Québec To: Ontario points served direct: 650 per mile, round trip.Modification of the clause b: The applicant clause 6 of whose permit 22406-V reads as follows: (6) Restricted trucking - long distance -restricted route - specialized units - (6) From the Québec-Ontario border (ports of entry: Hull, Pointe-Fortune and Rivière-Beaudette) to Montreal and all localities situated within a radius of 125 miles from the limits of said City, with the exclusion of Cowansville, Waterloo, Victoriaville, Arthabaska, Warwick, Princeville, Plessisville and Daveluyville, nnd return, for the transportation of new crated and uncrated furniture, lamps, pillows, upholstered goods including bedding, mattresses, cushions and furniture springs in specially designed drop-frame type moving vans, for and on behalf of the manufacturers of the said goods, to or from points, as authorized, in the Province of Ontario.Restriction re/Clause b: The above-mentioned service is to be operated solely in conjunction with a complementary certificate issued by the Ontario Highway Transport Board and dated May 16, 1972.wants the said clause 6 to read in the future as follows: (b) Restricted trucking - long distance -restricted route - specialized units - (b) From the Québec-Ontario border (ports of entry: Hull, Point-Fortune, Rivière-Beaudette, Judge, Cheminis) to Montreal and all localities situated within a radius of 125 miles from the limits of said City and return, for the transportation of new crated and new uncrated furniture, lamps, pillows, upholstered goods, bedding, mattresses, cushions, furniture springs and furniture components in specially-designed drop-frame type moving vans, for an on behalf of manufacturers, dealers and distributors of the said goods, to or from points, as authorized, in the Province of Ontario.Restriction re/clause b: The above-mentioned service is to be operated solely in conjunction with a complementary certificate issued by the Ontario Highway Transport Board and dated February 4, 1975. 3750 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Afay JO, J975, Vol.JOT, No.19 Rôle M-8P53 M-500157-D-004 ST-ANTOINE TRANSPORT ENRG.(M.Rémi Lagacé, opérant sous le nom de / operating under the name of: St-Antoine-sur-Richelieu (Verchères) (Que.) Rôle M-8054 M-500806-D-004 FILION & FRERES INC.800, boul.Lajeunesse Saint-Jérôme (Que.) Rôle M-8055 M-500806-D-003 FILION & FRERES INC.800, boul.Lajeunesse Saint-Jérôme (Que.) Rôle M-8056 M-506210-D-001 MAHONEY, ROGER Lacoste (Labelle) (Que.) Rôle M-8057 M-500745-D-001 LUSSIER, ANDRÉ 1175, Grand Rang St-François St-Hyacinthe (Que.) Rôle M-8058 M-505893-D-O01 CÔTÉ, GILLES 125, Chapais Châteauguay (Que.) Rôle M-8059 M-505934-D-001 POTVIN, LOUIS-PAUL 61, rue Cedar Granby (Que.) Rôle M-8060 M-504122-D-001 GAUTHIER, LÉO CP.266 Matagami (Que.) Rôle M-8061 M-504132-D-001 LAMARCHE, RENE 116, Cardinal-Bégin est Rouyn (Que.) Rôle M-8062 M-504506-D-001 CARLE, HUBERT 452, Murphy Gatineau (Que.) Rôle M-8063 M-506028-D-001 JOBIN, GÉRARD Landrienne (Abitibi) (Que.) La requérante demande à la Commission des transports du Québec de lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 06.The applicant requests the Québec Trans port Commission to issue him a bulk trucking permit, Contractor class, for Region ISO.uo.La requérante demande à la Commission des transports du Québec un permis de camionnage en vrac pour la région no 6 comme Entrepreneur pour le transport de sable et pierre concassée.La requérante demande à la Commission des transports du Québec un permis de camionnage en vrac pour la région no 6 comme Entrepreneur pour le transport de sable et pierre concassée.Le requérant, propriétaire de camion immatriculé au Québec avant le 14 avril 1972, demande à la Commission des transports du Québec de lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 07.Le requérant, qui possède une attestation M-500745-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 06.The applicant requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit for Region No.6, as Contractor for the transport of sand and crushed stone.The applicant requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit for Region No.6, as Contractor for the transport of sand and crushed stone.The applicant, owner of a truck registered in the Province of Québec before April 14, 1972, requests the Québec Transport Commission to issue him a bulk trucking permit.Contractor class, for Region No.07.The applicant, who holds certificate M-500745-D-001, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.06.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région no 06, pour transporter les matières suivantes: terre, pierre et sable.The applicant requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit, Artisan class, for Region No.06, to transport the following materials: earth, stone and sand.Personne physique, propriétaire de camion immatriculé au Québec depuis le 14 avril 1972, demande à la Commission des transports dp lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région no Individual person, owner of a truck registered in the Province of Québec since April 14, 1972, requests the Transport Commission to issue him a bulk trucking permit, Artisan class, for Region No.5.Le requérant, qui possède une attestation M-504122-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepremeur, pour la région no 08.The applicant, who holds certificate M-504122-D-001, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.08.Le requérant, qui possède une attestation M-504132-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 08.The applicant, who holds certificate M-504132-D-001, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.08.Le requérant, qui possède une attestation M-504605-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région no 07.The applicant, who holds certificate M-504505-D-001, requests a bulk trucking permit, Artisan class, for Region No.07s Le requérant, propriétaire de camion immatriculé au Québec depuis avril 1972, demande à la Commission des transports du Québec un permis de camionnage an vrac, catégorie Artisan, pour la région no 08.The applicant, owner of a truck registered in the Province of Québec since April 1972, requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit, Artisan class, for Region No.08. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1975.107' année, n° 19 3751 Rôle M-8064 M-505437-D-001 LALONDE, JACQUES 622, rue Watt Gatineau (Que.) Rôle M-8065 M-503247-D-001 Bl.EAU, ANDRÉ 407, boul.Edouard VII St-Philippe (Laprairie) (Que.) Rôle M-8066 M-504420-D-001 MONTREUIL, LÉON CP.332 Barraute (Abitibi-Est) (Que.) Rôle M-8067 M-504422-D-001 THURSTON, EDMUND St-Anicet (Huntingdon) (Que.) Rôle M-8068 M-505581-D-1 PAGE, PIERRE 16.rue Ste-Trinité Contrecoeur (Que.) Rôle M-S069 M-505581-D-2 PAGE, PIERRE 16.rue Ste-Trinité Contrecoeur (Que.) Rôle M-8070 M-50148O-D-OO1 LANDRY, RAYMOND CP.89 Tachereau (Abitibi) (Que.) Rôle M-8071 M-505854-D-001 BARIL, CILLES 201, rue Principale St-Damien-de-Brandon (Berthier) (Que.) Rôle M-8072 M-503132-D-O01 DOL, ANTOINE 95,rue Brodeur Dorion (Que.) Rôle M-8073 M-505176-D-001 MC CARTHY, RAOUL Grand-Remous (Gatineau) (Que.) Rôle M-8074 M-503095-D-001 MORIER, GUY St-Mathias (Rouville) (Que.) Le requérant, propriétaire de camion immatriculé au Québec depuis le 14 avril 1972, demande à la Commission des transporta du Québec de lui émettre un permis de camionnage en vrac pour la région no 7, catégorie Artisan.Le requérant, qui possède une attestation M-503247-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 10.The applicant, owner of a truck registered in the Province of Québec since April 14.1972, requests the Québec Transport Commission to issue him a bulk trucking permit for Region No.7, Artisan class.The applicant, who holds certificate M-503247-D-O01, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.10.Le requérant, qui possède une attestation M-504420-D-001.demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région no 08.The applicant, who holds certificate M-504420-D-001.requests a bulk trucking permit, Artisan class, for Region No.08.Le requérant, qui possède une attestation M-504422-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région no 06.The applicant, who holds certificate M-504422-D-001, requests a bulk trucking permit, Artisan class, for Region No.06.Le requérant, propriétaire de camions immatriculés au Québec depuis le 14 avril 1972, demande à la Commission des Transports du Québec de lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 06.Le requérant, propriétaire de camions immatriculés au Québec depuis le 14 avril 1972.demande à la Commission des transports du Québec de lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 06.Le requérant, qui possède une attestation M-501480-D-001.demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 08.The applicant, owner of trucks registered in the Province of Québec since April 14, 1972.requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.06.The applicant, owner of trucks registered in the Province of Québec since April 14, 1972, requests the Québec Transport Commission to issue a bulk trucking permit to him, Contractor class, for Region No.06.The applicant, who holds a certificate M-501480-D-001, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.08 Le requérant demande Ma Commission des The applicant requests from the Québec transports du Québec un permis de camion- Transport Commission a bulk trucking nageen vrac, catégorie Artisan, pourla région permit, Artisan class, for Region No.06.no 06.Le requérant, qui possède une attestation M-503132-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 10.The applicant, who holds a certificate M-503132-D-001, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.10.Le requérant, propriétaire de camion immatriculé au Québec depuis le 14 avril 1972, demande à la Commission des transports du Québec de lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 07.Le requérant, qui possède une attestation M-503095-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région no 06.The applicant, owner of a truck registered in the Province of Québec since Aprii 14.1972, requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.07.The applicant, who holds certificate No.M-503095-D-001.requests a bulk trucking permit, Artisan class, for Region No.06. 3752 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1976, Vol.107, No.19 Rôle M-8075 M-504479-D-001 LES TRANSPORTS VAL D'OR INC.Chemin Fournière Malartic (Abitibi) (Que.) Rôle M-8076 M-504479-D-002 LES TRANSPORTS VAL D'OR INC.Chemin Fournière Malartic (Abitibi) (Que.) Rôle M-8077 M-502965-D-O41 LEAVOY MINES SERVICES LTD.351.10e Avenue est Amos (Que.) Rôle M-8078 M-502965-D-042 LEAVOY MINES SERVICES LTD.351.10e Avenue est Amos (Que.) Rôle M-8079 M-502965-D-043 LEAVOY MINES SERVICES LTD.351, 10e Avenue est Amos (Que.) Rôle M-8080 M-502965-D-004 LEAVOY MINES SERVICES LTD.351, 10e Avenue est Amos (Que.) Rôle M-8081 M-502965-D-045 LEAVOY MINES SERVICES LTD.351, 10e Avenue est Amos (Que.) Rôle M-8082 M-502965-D-046 LEAVOY MINES SERVICES LTD.Rôle M-8083 M-504728-D-001 MOLLOY, PALM A St-Emile-de-Suffolk (Papineau) (Que.) Rôle M-8084 M-5021Ô9-D-0O1 LAJEUNESSE, JACQUES Montcerf (Gatineau) (Que.) Rôle M-8085 M-500117-D-001 DEMERS, JEAN 501, Codère, app.no 5 Sherbrooke (Que.) La requérante, qui possède une attestation M-604479-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 08.La requérante, qui possède une attestation M-504479\u2014D\u2014002, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 08.La requérante demande à la Commission des transports du Québec de lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 08.La requérante demande à la Commission des transports du Québec de lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 08.La requérante demande à la Commission des transports du Québec de lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 08.La requérante demande à la Commission des transports du Québec de lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 08.La requérante demande à la Commission des transports du Québec de lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 08.La requérante demande à la Commission des transports du Québec de lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 08.Le requérant, qui possède une attestation M-504728-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 07.Le requérant, qui possède une attestation M-502139-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 07.Le requérant, qui possède une attestation M-500117-D-001, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région no 05.The applicant, which holds cert ficate M-504479-D-O01.requests a bulk trucking permit.Contractor class, for Region No.u».The applicant, which holds certificate M-504479-D-002, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.08.The applicant requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.08.The applicant requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.08.The applicant requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.08.The applicant requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.08.The applicant requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.08.The applicant requests the Québec Transport Commission to issue a bulk trucking permit to it, Contractor class, for Region ,.T,1!,e_\u201ey>Çl'cant' who ho'ds certificate M-6O4728-D-001, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.07.,.TiîS,.^.pÇllcant' who holds certificate M-502139-D-001, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.07.™T£™, ,.\\ppi.ic£nt' who holds certificate M-500117-D-001, requests a bulk trucking permit, Artisan class, for Region No.06. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1976, 10T année, n° 19 3753 Rôle M-8086 M-503183-D-001 CLAVEAU, GEORGES 1736.Barbe, app.4 Chomedey ViUe de Laval (Que.) Rôle M-8087 M-506182-D-O01 BÊLIVEAU, D1EUDONNÉ 1390, Dorval Sherbrooke (Que.) Rôle M-8088 M-506210-D-002 MAHONEY, ROGER Lacoste (Labelle) (Que.) Rôle M-8089 21339-V-D-7 DEL TRANSPORT LIMITÉE 386, Richelieu McMasterville (Verchères) (Que.) Le requérant, qui possède une attestation M-503183-D-O01.demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 10.Le requérant, propriétaire de camion immatriculé au Québec depuis le 14 avril 1972, demande à la Commission des transports du Québec un permis de camionnage, catégorie Artisan, pour la région no 05.Le requérant, propriétaire de camion immatriculé au Québec avant le 14 avril 1972, demande à la Commission des transports du Québec de lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 07.Modification : La partie requérante dont les clauses a, h et j, ainsi que les droits additionnels rattachés auxditea clauses qui se lisent comme suit: a) Transport restreint - longue distance -route restreinte - a) De Beloeil et Valleyfield à tous les endroits dans les districts électoraux-provinciaux d'Abitibi-Est, Abitibi-Ouest et Témis-camingue, pour le transport d'explosifs pour le compte des compagnies minières en général (pas de transbordement).Service additionnel: En donnant le service autorisé par la clause a de son permis, la détentrice est autorisée à desservir Chibougamau et Chapais, sauf pour le transport d'explosifs provenant de Beloeil.nonobstant les dispositions de 'Ordonnance générale du 30 janvier 1957.h) Transport restreint - longue distance -route restreinte - h) Des frontières Québec-Ontario (ports d'entrée: Cheminis.Notre-Dame-du-Nord et Témiscamingue) a tous les endroits situés dans les districts électoraux provinciaux d'Abitibi-Est, Abitibi-Ouest et Témisca-mingue, pour le transport d'explosifs et de substances servant au dynamitage (blasting agent) provenant de Nobel, Ontario (pas de transbordement).y) Transport restreint - longue distance -route restreinte - ;') De tous les endroits situés dans les districts électoraux provinciaux d'Abitibi-Est Abitibi-Ouest et Témiscamingue, à tous les endroits situes dans lesdits comtés, pour le transport d'explosifs (pas de transbordement).Droits additionnels: En donnant les services autorisés par les clauses h et j de ce permis, la détentrice est autorisée à desservir Chibougamau et Chapais, sauf pour le transport d'explosifs provenant de Beloeil, nonobstant les dispositions de l'Ordonnance générale no 5729 du 30 janvier 1967.s'adresse à la Commission afin d'être autorisée à modifier ces services additionnels pour qu'ils se lisent à l'avenir comme suit: En donnant le service autorisé par la clause a de son permis, la détentrice est autorisée à desservir Chibougamau et Chapais, nonobstant les dispositions de l'Ordonnance générale du 30 janvier 1967.The applicant, who holds certificate M-503183-D-001, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.10.The applicant, owner of a truck registered in the Province of Québec since April 14, 1972, requests from the Québec Transport Commission a trucking permit, Artisan class, for Region No.06.The applicant, owner of a truck registered in the Province of Québec before April 14.1972.requests the Québec Transport Commission to issue him a bulk trucking permit.Contractor class, for Region No.07.Modification: The applicant, which holds a permit in which clauses a, h, j and the additional rights attaching to said clauses read as follows: (a) Restricted trucking - long distance -restricted route - (a) From Beloeil and Valleyfield to any point located in the Provincial Electoral District of Abitibi-East, Abitibi-West and Témiscamingue, for the transport of explosives, on behalf of mining companies in general (no transhipment).Additional service: When providing the service authorized under the terms of clause a of its permit, the holder is authorized to serve Chibougamau and Chapais.except for the transport of explosives originating from Beloeil.notwithstanding the provisions of the General Order, dated January 30.1957.(n) Restricted trucking - long distance -restricted route - (A) From the Québec-Ontario border (ports of entry: Cheminis, Notre-Dame-du-Nord and Témiscamingue) to any point located in the Provincial Electoral Districts of Abitibi-East, Abitibi-West and Témiscamingue, for the transport of explosives and blasting agents originating from Nobel, Ontario (no transhipment).(J) Restricted trucking - long distance -restricted route - (j) From any point located in the Provincial Electoral Districts of Abitibi-East, Abitibi-West and Témiscamingue, to any point located in said Counties, for the transport of explosives (no transhipment).Additional rights: When providing the service authorized under the terms of clauses h and ; of this permit, the holder shall be authorized to serve Chibougamau and Chapais except for the transport of explosives originating from Beloeil, notwithstanding the provisions of General Order No.5729, dated January 30.1967.requests from the Commission authorization to modify said additional rights to read as follows in the future: When providing the service authorized under the terms of clause a of its permit, the holder shall be authorized to serve Chibougamau and Chapais, notwithstanding the provisions of the General Order, dated January 30.1957. 3754 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 En donnant les services autorisés par les clauses h et j de ce permis, la détentrice est autorisée à desservir Chibougamau et Chapais, nonobstant les dispositions de l'Ordonnance générale no 5729 du 30 janvier 1957.When providing the services authorized under the terms of clauses h and j o! tnis permit, the holder shall be authorized to serve Chibougamau and Chapais, notwithstanding the provisions of General Order No.5729, dated January 30, 1957.Rôle M-8093 3556-A-D-4 LES AUTOBUS ROLAND INC.430, rue De Maitigny St-Jérôme (Que.: BRUNET & CLOUT1ER INC.986, Des Lacs Bellefeuille (Que.) La requérante-venderesse, Les Autobus Roland Inc., demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation de vendre, céder, transporter au requérant-acquéreur, Brunet & Cloutier Inc.tous les droits, titres, intérêts et privilèges qu'elle possède en vertu du permis 3556-A des dossiers de la Commission des transports du Québec, par lequel elle est autorisée à donner le service d'autobus urbain dans les limites de la cité de Bellefeuille.The applicant-vendor.Les Autobus Roland Inc., requests from the Québec Transport Commission authorization to sell, convey and transfer to the applicant-purchaser, Brunet & Cloutier Inc., all the rights of ownership, interest and benefits which it holds pursuant to permit 3556-A filed with the Québec Transport Commission, whereby the applicant-vendor is authorized to provide a city bus service within the limits of the City of Bellefeuille.Rôle M-8094 1411-DY-D-l BÉRUBÊ, YVES 267.chemin Milton Beaconsfield (Que.) Nouvelle demande: Le requérant s'adresse à la Commission des transports du Québec dans le but d'être autorisé à donner le service de location suivant: Location à court terme (moins d'une année) de maison motorisée au public en général au no 267, chemin Milton, Beaconsfield (Que.).New Application: The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following leasing service: Short-term leasing (less than one year) of mobile homes to the general public, at 267, Milton Road, Beaconsfield, P.Q.Rôle M-8095 2053-DYV-D-l ST-FRANÇOIS LEASING REG'D.ST-FRANÇOIS LOCATION ENRG.(Claude Monette faisant affaires sous la raison sociale de / doing business under the name of: 8840, Pie IX Montréal (Que.» Nouvelle demande: Service 1 : La requérante demande à être autorisée à faire la location à court terme de véhicules de commerce et de livraison (camions, camions-tracteurs, remorques), pour le public en général.Service 2: La requérante demande à être autorisée à faire la location à long terme de véhicules de commerce et de livraison (camions, camions-tracteurs, remorques), pour le public en général.New application: Service 1: The applicant requests authorization to lease, on a short-term basis, commercial and delivery vehicles (trucks, tractors and trailers), to the public at large.Service 2 : The applicant requests authorisation to lease commercial and delivery vehicles (trucks, tractor trucks and trailers), on a long-term basis, to the public at large.Rôle M-8099 M-204809-D-2 WALTHO, HELEN 8, Valois Circle Pointe-Claire (Que.) et/and M-206375 BRISEBOIS, PAUL Demande de transfert: Waltho, Helen, demande à la Commission de transférer à: Brisebois, Paul 43.chemin Lakeshore Pointe-Claire (Que.) le permis no M-204809-D-2 qu'elle détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-12, Ouest de Montréal.Application for transfer : Waltho, Hehn, requests the Commission to transfer to: Brisebois, Paul 43 Lakeshore Road Pointe-Claire, P.Q.permit No.M-204809-D-2, which she holds, to effect transport by taxicab in Conglomeration A-12, West of Montreal.Rôle M-8100 M-205895 CRITICOS, ANTOINETTE 456, Viviane Ville Mont-Royal (Que.) et/and M-201790-D-3 Rôle M-8101 M-200702 LÊPINE, VÉRONIQUE 6561, boul.Galerie D'Anjou app.4, Anjou (Que.) et/and M-206379 NADEAU, MAURILL Demande de transfert: Criticos, Antoinette, demande à.la Commission de transférer à: Valaveris, Marc 6585, Garnier, app.3 Montréal (Que.) le permis no M-205895 qu'elle détient, pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll.Montréal.Demande de transfert: Lépine, Véronique, demande à la Commission de transférer à: Nadeau, Maurill 2276, Lebrun Montréal (Que.) le permis no M-200702 qu'elle détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll, Montréal.Application for transfer: priticos.Antoinette, requests the Commission to transfer to: Valaveris.Marc 6585 Garnier, Apt.3 Montreal, P.Q.permit No.M-205895, which she holds, to effect transport by taxicab in Conglomeration A-ll, Montreal.Application for transfer: Lépine, Véronique, requests the Commission to transfer to: Nadeau, Maurill 2276 Lebrun Montreal, P.Q.permit No.M-200702, which she holds, to effect transport by taxicab in Conglomeration A-ll, Montreal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3755 Rôle M-8102 M-204095-D-2 LARICHELI ÈRE, RAYMOND 2315.Duff Court, app.21 Lachine (Qué.1 et/and M-206363 LANGEVIN.JACQUES Rôle M-8103 M-208381 LAFLEUR, DANIEL 2167, Auclair St-Vincent-de-Paul (Que.) et/and M-206364 ROBERT, RENÉ Rôle M-8104 M-200773 VENDETTI.MARCELLE MME 1105, Berthelet Longueuil (Que.) et/and M-206378 DORÉ, ROBERT Rôle M-8105 M-203955-D-2 GAGNON,YVON 319, Lulli Laval-des-Rapides (Que.) et/and M-206370 HASROUNY, MOUSSA Rôle M-8106 ROY, JEAN 404, Maisonneuve St-Jean (Que.) et/and M-206368 NICHOLSON, GORDON Rôle M-8107 M-204797 SCHVIMMER, SOLOMON 535, avenue Wiseman Outremont (Que.* et/and M-206352 LADIK, WILLIAM Rôle M-8108 M-206100 BEAUCHAMP, FERNANDE 430, Parker Aylmer (Que.) et/and M-206313 PAQUETTE.HECTOR Rôle M-8109 M-205509 DAKIN, ERROL GUY 5665.Parnasse Brossard (Que.) et/and Demande de transfert: Larichelière, Raymond, demande à la Commission de transférer à: Langevin, Jacques 70, rue Laplante St-Constant (Que.) le permis no M-204095-D-2 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-12, Ouest de Montréal.Demande de transfert: LaSeur, Daniel, demande à la Commission de transférer à: Robert, René 1100, De Callières Duvernay (Que.) le permis no M-203381 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-8, Laval.Demande de transfert: Vendetti, Marcelle Mme.demande à la Commission de transférer à : Doré, Robert 602, chemin de la Montagne St-Hilaire (Que.) le permis no M-200773 qu'elle détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll.Montréal.Demande de transfert: Gagnon.Yvon.demande à la Commission de transférer à: Hasrouny, Moussa 2685, avenue Kent, app.303 Montréal (Que.) le permis no M-203955-D-2 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans i'agglomération A-ll, Montréal.Demande de transfert: Roy, Jean, demande à la Commission de transférer à : Nicholson, Gordon 521, Lalemant St-Jean (Que.) le permis no M-203663-D-12 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-41, St-Jean.Demande de transfert: Schvimmer, Solomon, demande à la Commission de transférer à: Ladik, William 5545, côte St-Luc, app.50 Montréal (Que.) le permis no M-204797 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll, Montréal.Demande de transfert: Beauchamp, Fernande, demande à la Commission de transférer à: Paquette, Hector 426, Parker Aylmer (Que.) le permis no M-206100 qu'elle détient pour effectuer du transport de taxi dans la région de Lucerne, 78-03-03-VT-2, comprenant Aylmer, Deschênes, Lucerne.Demande de transfert: Dakin, Errol Guy, demande à la Commission de transférer à: Muller.Meier 5761, Honoré-de-Balzac Côté-St-Luc 1209 (Que.) Application for transfer: Larichelière, Raymond, requests the Commission to transfer to: Langevin, Jacques 70 Laplante Street St-Constant, P.Q.permit No.M-204095-D-2.which he holds, to effect transport by taxicab in Conglomeration A-12, West of Montreal.Application for transfer: Lafleur.Daniel, requests the Commission to transfer to: Robert, René 1100 De Callières Duvernay, P.Q.permit No.M-203381, which he holds, to effect transport by taxicab in Conglomeration A-8, Laval.Application for transfer : Vendetti, Mrs.Marcelle, requests the Commission to transfer to: Doré, Robert 602 de la Montagne Road St-Hilaire, P.Q.permit No.M-200773, which she holds, to effect transport by taxicab in Conglomeration A-ll, Montreal.Application for transfer: Gagnon, Yvon, requests the Commission to transfer to: Hasrouny, Moussa 2685 Kent Avenue, Apt.303 Montreal.P.Q.permit No.M-203955-D-2.which he holds, to effect transport by taxicab in Conglomeration A-ll, Montreal.Application for transfer: Roy, Jean, requests the Commission to transfer to: Nicholson, Gordon 521 Lalemant St-Jean, P.Q.permit No.M-203663-D-12, which he holds, to effect transport by taxicab in Conglomeration A-41, St-Jean.Application for transfer: Schvimmer, Solomon, requests the Commission to transfer to: Ladik.William 5545 Côte St-Luc.Apt.50 Montreal.P.Q.permit No.M-204797, which he holds, to effect transport by taxicab in Conglomeration A-ll, Montreal.Application for transfer: Beauchamp, Fernande, requests the Commission to transfer to: Paquette, Hector 426 Parker Aylmer, P.Q.permit No.M-206100, which she holds, to .effect transport by taxicab in the Region of Lucerne.78-03-03-VT-2.comprising Aylmer, Deschènes and Lucerne.Application for transfer: Dakin, Errol Guy.requests the Commission to transfer to: Muller.Meier 5761 Honoré-de-Balzac Côte-St-Luc, 1209, P.Q. 3756 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1974, Vol.107, No.19 M-200482-D-3 ML'LLER.MEIER Rôle M-8110 M-203286 GAETJENS, FRANK 10454, Leblanc Montréal-Nord (.Que.) et/and M-2061S3-D-2 HOSRI, ÉMILE Rôle M-8111 M-201313-D-23 AMAR ENTREPRISES INC.1250, Jeanne-Mnnce Montréal (Que.) et/and M-206365 MORAIS, MATHILDE Rôle M-8112 M-205518 REBOH, JOSEPH 492, Robertson Ville St-Laurent (Que.) Rôle M-8113 M-204448-D-6 SHAMSHER, SINGH 2188, Lapierre LaSalle (Que.) Rôle M-8114 M-500860-D-001 TRACY TRANSPORT INC.671, route Marie-Victorin Sorel (Que.) M-502473-D-002 HÉBERT, RICHARD 6, rue Taillon Sorel (Qué.ï Rôle M-8116 M-502768-D-001 FOURNELLE, ÊMILE 83, boul.Ste-Anne Ste-Anne-Des-Plainea (Terrebonne) (Que.) M-506162-D-001 CHARTRAND, RICHARD 238, Clément Ste-Anne-Des-Plainea (Terrebonne) (Que.) Rôle M-8116 M-502057-D-001 TREMBLAY, RICHARD 401, 90e Avenue Lasalle Montréal (Que.) M-502915-D-002 MAISONNEUVE, ALFRED 406, rue Dawn Lasalle Montréal (Que.) le permis no M-205509 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll, Montréal.permit No.M-205509.which he h»1*»' t° effect transport by taxicab in Conglomeration A-ll, Montreal.Demande de transfert: Gaetjens, Frank, demande à la Commission de transférer à: Hosri, Emile 4815, chemin de la Reine Marie, app.6 Montréal.(Que.) le permis no M-203286 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll.Montréal.Demande de transfert: Amar Entreprises Inc.demande à la Commission de transférer à: Morais, Mathilde 2816, Barclay Montréal, (Que.) le permis no M-201313-D-23 qu'elle détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll, Montréal.Application for transfer: Gaetjens, Frank, requests the Commission to transfer to: Hosri, Emile 4815 Queen Mary Road, Apt.6 Montreal.P.Q.permit No.M-203286, which he holds, to effect transport by taxicab in Conglomeration A-ll, Montreal.Application for transfer: Amar Entreprises Inc.requests the Commission to transfer to: Moral.-.Mathilde 2816 Barclay Montreal, P.Q.permit No-201313-D-23, which it holds, to effect transport by taxicab in Conglomeration A-ll, Montreal.Nouvelle demande : La partie requérante demande à la Commission un permis de propriétaire pour effectuer par véhicule-taxi du transport dans l'agglomération A-ll.Montréal.New application: The applicant requests from the Commission an owner's permit to effect transport by taxicab in Conglomeration A-ll, Montreal.Nouvelle demande: La partie requérante demande à la Commission un permis de propriétaire pour effectuer par véhicule-taxi du transport dans l'agglomération A-ll.Montréal.New application: The applicant requests from the Commission an owner's permit to effect transport by taxicab in Conglomeration A-ll, Montreal.Demande de transfert: La requérante-cédante demande à la Commission de transférer à: Hébert.Richard 6, rue Taillon Sorel (Que.) l'attestation ou le permis no M-500860-D-001 qu'elle détient pour effectuer du camionnage en vrac, dans la région no 6, catégorie Entrepreneur.Application for transfer: The applicant-transferror requests the Commission to transfer to: Hébert, Richard 6 Taillon Street Sorel, P.Q.certificate or permit No.M-500860-D-001, which it holds, to effect bulk trucking in Region No.6.Contractor class.Demande de transfert: Le requérant-cédant demande à la Commission de transférer à: Chartrand, Richard 238, Clément Ste-Anne-des-Plaines (Terrebonne) (Que.) l'attestation ou le permis no M-502768-D^OOl qu'il détient pour effectuer du camionnage en vrac dans la région no 6, catégorie Artisan.Application for transfer: The applicant-transferror requests the Commission to transfer to: Chartrand, Richard 238 Clément Ste-Anne-des-Plaines Terrebonne, P.Q.certificate or permit No.M-502768-D-001, which he holds, to effect bulk trucking in Region No.6.Artisan class.Demande de transfert: Le requérant-cédant demande à la Commission de transférer à: Maisonneuve, Alfred 406, rue Dawn Lasalle Montréal (Que.) l'attestation ou le permis no M-502057-D-001 qu'il détient pour effectuer du camionnage en vrac dans la région no 10.catégorie Artisan.Application for transfer: The applicant-transferror requests the Commission to transfer to: Maisonneuve, Alfred 406 Dawn Street Lasalle Montreal, P.Q.certificate or permit No.M-502057-D-001, which he holds, to effect bulk trucking in Region No.10, Artisan class. GAZETTE OFFICTELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3757 Rôle M-8117 M-502858-D-O01 OUELLETTE, RAYNALD 923,rue 50 Pointe-Calumet (Deux-Montagnes) (Que.) M-505494-D-002 DUFRESNE, YVON 31, 2e Avenue St-Janvier (Terrebonne) (Que.) Rôle M-8118 M-501536-D-O03 BÉLANGER & FILS INC.C P 6 Rouyn (Que.) M-50626O-D-0O1 BÉLANGER, MICHEL R.R.no 1 Rouyn (Que.) Rôle M-8119 M-504780-D-001 FLEURANT, ANDRÉ CP.107 Lac Carré (Terrebonne) (Que.) M-500668-D-O01 LEGAULT, ROSARIO R.R.no 1 St-Jovite (Terrebonne) (Que.) Rôle M-8120 M-503433-D-O01 LAFOREST, CLAUDE 1, Romuald-Dalphon St-Charles-Borromée (Joliette) (Que.) M-506172-D-001 PERREAULT, PIERRE 2580, La Chaloupe Ste-Elisabeth (Joliette) (Que.) Rôle Q-3486 443-V-D-7 HARVEY TRANSPORT LIMITÉE/LIMITED 2900.avenue 1 du Pont Sud CP.580 Alma (Que.) Rôle Q-3487 4732-V-D-5 GRENIER TRANSPORT INC.Route Chassé CP.700 Ste-Marie (Beauce) (Que.) Demande de transfert: Le requérant-cédant demande à la Commission de transférer à : Dufresne, Yvon 31, 2e Avenue St-Janvier (Terrebonne) (Que.) l'attestation ou le permis no M-502858-D-001 qu'il détient pour effectuer du camionnage en vrac dans la région no 10, catégorie Artisan.Demande de transfert: La requérante-cédante demande à la Commission de transférer à: Bélanger, Michel R.R.no 1 Rouyn (Que.) l'attestation ou le permis no M-501536-D-003 qu'elle détient pour effectuer du camionnage en vrac dans la région no 8, catégorie Entrepreneur.Demande de transfert: Je, soussigné, André Fleurant, bénéficiant de l'attestation suivante: Région 6 Attestation no M-604780-D-1 Chevrolet 1965 Série no 5C 6303803409 Licence no F-158264 - 1974 demande à la Commission des transports du Québec de transférer cette attestation à M.Rosario Legault, R.R.no 1 St-Jovite, comté de Terrebonne, pour opérer le service de camionnage en vrac, dans la région no 6.Demande de transfert: Le requérant-cédant demande à la Commission de transférer à: Perreault, Pierre 2580.La Chaloupe Ste-Elisabeth (Joliette) (Que.) l'attestation ou le permis no M-503433-D-001 qu'il détient pour effectuer du camionnage en vrac dans la région no 6, catégorie Artisan.Modification de permis: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation de donner le service de transport suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - régulier - contrat - De la gare Centrale du Canadien National de Montréal à la gare du Canadien National à Jonquière et retour, pour le transport de marchandises pour le compte de la Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada.Droit additionnel : En donnant le service précité, la détentrice est autorisée à donner un service de cueillette et de livraison de marchandises à Jonquière, Kénogami, Chicoutimi et Arvida.Modification de permis: La partie requérante qui détient la clause c suivante: c) Transport général - longue distance -route restreinte - irrégulier - c) De Ste-Marie-de-Beauce, Scott et St-Bernard à Montréal, et retour.Application for transfer : The applicant-transferror requests the Commission to transfer to: Dufresne.Yvon 31-2nd Avenue St-Janvier Terrebonne.P.Q.certificate or permit No.M-502858-D-001.which he holds, to effect bulk trucking in Region No.10, Artisan class.Application for transfer: The applicant-transferror requests the Commission to transfer to : Bélanger, Michel R.R.No.1 Rouyn, P.Q.certificate or permit No.M-601536-D-O03, which it holds, to effect bulk trucking in Region No.8, Contractor class.Application for transfer: I, the undersigned, André Fleurant, holder of the following certificate: Region 6 Certificate No.M-604780-D-1 Chevrolet 1965 Serial No.5C 6303803409 License No.F-158264 - 1974 do request the Québec Transport Commission to transfer said certificate to Mr.Rosario Legault, R.R.No.1, St-Jovite, County of Terrebonne, to operate a bulk trucking service in Region No.6.Application for transfer: The applicant-transferror requests the Commission to transfer to: Perreault, Pierre 2580 La Chaloupe Ste-Elisabeth.County of Joliette, P.Q.certificate or permit No.M-5O3433-D-O01, which he holds, to effect bulk trucking in Region No.6, Artisan class.Modification of permit: The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following transport service : Restricted trucking - long distance -restricted route - regular - contract \u2014 From the Canadian National Railways Central Station in Montreal to'the Canadian National Railways Station in Jonquière and return, for the transport of goods on behalf of the Canadian National Railways.Additional right : When providing the service hereinabove mentioned, the holder shall be authorized to provide a service involving the pick-up and delivery of goods in Jonquière, Kénogami, Chicoutimi and Arvida.Modification of permit: The applicant, holder of a permit in which clause c reads as follows : (c) General trucking - long distance -restricted route - irregular - (c) From Ste-Marie-de-Beauce, Scott and St-Bernard to Montreal, and return. 3758 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107.Ko.19 Rôle Q-3488 1414-DY-D-l G.ST-ARNAULD AUTOMOBILES INC.1590.de la Canardière Québec (Que.) Rôle Q-3489 Q-24000-D-2-TF LA LIGUE DE TAXIS DE RIV1ÈRE-DU-LOUP INC.5, rue de la Chute Rivière-du-Loup (Que.) G5R 2VI Rôle Q-3490 159S7-V-D-26 TRUST GÉNÉRAL DU CANADA 1091.chemin St-Louis Sillery (Que.) Siège social / Head office : Montréal Partie requérante / Applicant et/and GÉRARD NOL1N LTÉE 150.de l'Eglise St-Jean-Chrysostome (Lévis) (Que.) demande à la Commission des transports de Québec l'autorisation de donner le service suivant: c) Transport général - longue distance -route restreinte - irrégulier - c) De Ste-Marie-de-Beauce, Scott et St-Bernard à Montréal et Mirabel, et retour.Nouvelle demande: La partie requérante demande a la Commission des transports du Québec l'autorisation de donner les services de location suivants: Service 1: Location à court terme de véhicules de promenade pour accommoder la clientèle dans l'attente : o) d'une voiture en réparation prolongée causée par manque de pièces ou autres: b) de prendre livraison d'une voiture achetée et non en mains.Service 2 : .Location à long terme de véhicules de promenade pour le public en général.La requérante demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation d'augmenter les tarifs pour le transport par véhicules taxis dans l'agglomération de Rivière-du-Loup (A-13).Taux actuels Present rates The applicant requests from *.he,9\"éb*« Transport Commission authorization to provide the following service: (c) General trucking - long distance -restricted route - irregular - , (c) From Ste-Marie-de-Beauçe.Scott and St-Bernard to Montreal and Mirabel, and return.New application : The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following leasing services: Service 1: Leasing of pleasure vehicles, on a short-term basis in order to serve its customers awaiting: (a) a vehicle whose repair is being delayed owing to the non-availability of parts, or for other reasons; (b) the delivery of a new vehicle bought but not available.Service 2 : Leasing of pleasure vehicles on a long-term basis for the public at large.The applicant requests from the Québec Commission authorization to increase its tariffs for transport by taxicab in the Conglomeration of Rivière-du-Loup (A-13).so oo 0.60 0.10 Au départ / Minimum departure tariff Au mille parcouru / Per mile travelled La minute d'attente / Each minute oj waiting Taux proposés Proposed rates jo.70 0.60 0.20 Requête pour transfert do permis de Gérard Noiin Ltée.A cette Honorable Cour, le requérant expose: 1.Il est fiduciaire pour les porteurs d'obligations de Gérard Noiin Ltée aux termes d'un acte de fiducie reçu devant Me Georges Tas-chereau.notaire, le 16 mai 1972 et enregistré à Lévis le 18 du même mois, sous le numéro 167809, dont copie est produite au soutien des présentes sous la cote RI comme si elle était ici au long récitée.2.Il est aussi fiduciaire pour les porteurs d'obligations de Gérard Noiin Ltée aux termes d'un acte de fiducie reçu devant Me Jean Mousseau.notaire, le 29 mai 1974 et enregistré le 3 juin de la même année à Lévis.sous le numéro 181988, à Rimouski, sous le numéro 171338 et à Chicoutimi, sous le numéro 274156; copie de cet acte de fiducie est produite au soutien des présentes sous la cote R 2 comme si elle était ici au long récitée.3.Lesdits actes de fiducie ont hypothéqué, nanti et gagé les biens de la compagnie débitrice, pour les sommes y indiquées, au bénéfice des porteurs d'obligations et jusqu'à concurrence des sommes dues à ces derniers, pour la garantie des avances faites par iceux.4.Le 4 octobre 1974, le débiteur Gérard Noiin Ltée devait et était en défaut de payer aux porteurs d'obligations, La Banque Canadienne Nationale, la somme totale de $2,606,426,63, et le fiduciaire a dû prendre possession des biens hypothéqués, nantis et mis en gage, tel que constaté par un acte de prise de possession reçu devant le notaire, Denis Roy, le 4 octobre 1974, sous le numéro 727 de ses minutes et enregistré au bureau Application for transfer of permits held by Gérard Noiin Ltée The applicant alleges before this Honourable Tribunal that: 1.It is the trustee for the shareholders of Gérard Noiin Ltée, under the terms of a trust deed executed before Mr.Georges Taschereau, notary, on May 16, 1972 and registered in Levis on the 18th of same month, under number 167809; a copy of said deed is filed as Exhibit Rl in support of these presents as if it were recited herein in full.2.It is also the trustee for the shareholders of Gérard Noiin Ltée, under the terms of a trust deed executed before Mr.Jean Mousseau, notary, on May 29, 1974 and registered on June 3 of the same year: in Levis under number 181988, in Rimouski, under number 171338, and in Chicoutimi, under number 274156; a copy of said deed is filed as Exhibit R2 in support of these presents as if it were recited herein in full.3.The property of the debtor was mortgaged, secured and pledged by said trust deeds, for the benefit of the shareholders, for the amount indicated therein, amounting to but not exceeding the sums owing to the latter, as a guarantee for the advances made by the shareholders.4.On October 4.1974.the debtor, Gérard Noiin Ltée, was due to pay the aggregate amount of $2,606,426.63 to the shareholders.Bank Canadian National; but failed to pay such sum; and the trustee took over the possession of such property, which had been mortgaged, secured and pledged, as established by a deed of entry upon possession executed before Denis Roy, notary, on October 4, 1974, under number 727 of his GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n°J9 3759 d'enregistrement de Lévis, le 8 octobre sous le numéro 184,569.Ledit acte de prise de possession est produit au soutien des présentes sous la cote R 3 comme si elle était ici au long récitée.5.La constation du défaut du débiteur et la prise de possession des biens ont été faites conformément aux actes de fiducie auxquels il est référé ci-haut, et confèrent au fiduciaire les droits et avantages qui y sont stipulés au bénéfice des créanciers du débiteur, suivant leur rang respectif de priorité.6.Les biens hypothéqués, nantis et mis en gage étaient employés par le débiteur à l'exploitation de l'entreprise de transport de marchandises, aux conditions décrites aux permis émis en faveur dudit débiteur.7.Il est devenu nécessaire et urgent que le fiduciaire soit autorisé à exploiter en son nom, ès-qualité de fiduciaire des porteurs d'obligations, aux conditions des actes de fiducie, les permis que détient Gérard Noiin Ltée.8.Les permis d'exploitation de l'entreprise Gérard Noiin Ltée représentent, pour le fiduciaire, la capacité de gagner un revenu d'exploitation des biens dont il a maintenant la garde, pour le bénéfice des créanciers, suivant leur rang respectif de priorité.9.Le fiduciaire a l'intention de continuer l'exploitation de l'entreprise du débiteur pour le compte des créanciers, subordonné-ment aux conditions de l'acte de fiducie et de la loi, si l'autorisation à cette fin lui est accordée.10.Il est d'intérêt public que le service de transport de marchandises très spécialisées, mis en disponibilité par le débiteur, continue d'être offert à la clientèle qu'il dessert.11.Il est d'intérêt public que la présente requête soit accordée.Pourquoi, le requérant conclut à ce qu'il soit donné acte de la prise de possession des biens de Gérard Noiin Ltée, aux termes et conditions des actes de fiducie des 16 mai 1972 et 29 mai 1974 auxquels il est référé ci-haut, et de la loi; à ce que les permis détenus par Gérard Noiin Ltée soient transférés au fiduciaire, ès-qualité, et à ce que ce dernier soit autorisé à continuer aux conditions d'iceux, l'exploitation des biens dont il a maintenant la possession; le tout conformément à la loi, au bénéfice des créanciers, suivant leur rang respectif de priorité et aux autres conditions qu'il plaira au Tribunal d'imposer.Le permis de transport 15957-V se lit comme suit: a) Transport restreint - longue distance -route restreinte - a) De Montréal à Québec et dans un rayon de cent (100) milles de ladite ville, sauf les districts électoraux provinciaux de Chi-coutimi, Jonquière, Kénogami, Lac-St-Jean, Roberval et le district de Chibougamau.6) Transport restreint - longue distance -route restreinte - b) De Montréal à tous les points de la province de Québec situés à l'est de la ville de Québec, sauf les districts électoraux provinciaux de Lac-Sfc-Jean.Roberval, Jonquière Kénogami et Chicoutimi.Restriction: Dans le cas des clauses a et b, pour le transport, par camions citernes, d'huile pour as- minutes, and registered at the Lévis Registry Office, on October 8, under number 184, 569.The said deed of entry upon possession is filed as Exhibit R3 in support of these presents as if it were recited herein in full.5.The recording of the debtor's default of payment and the entry upon possession of the property were effected in conformity with the terms of the aforementioned trust deeds; the trustee was thereby vested with the rights and interests stipulated in said deeds, for the benefit of the debtor's creditors, according to their respective preference.6.The property which has been mortgaged, secured and pledged was used by the debtor for the operation of a commodity transport business, under the conditions described in the permits issued to said debtor.7.It has become necessary and urgent for the trustee to be authorized to operate in its own name the permit held by Gérard Noiin Ltée, in its capacity as trustee for the shareholders, under the terms of the aforesaid trust deeds.8.The operating permits of Gérard Noiin Ltée imply, for the trustee, the capacity of deriving an operating income from the property now vested in it, for the benefit of the creditors, according to their respective preference.9.The trustee, if authorized to do so, intends to carry on the operation of the business undertaking of the debtor on behalf of the creditors, subject to the terms of the trust deed and according to law.10.It is in the public interest that the transport service for goods of a very special nature, which was made available by the debtor, continue to be offered to the customers that it serves.11.It is in the public interest that the present request be granted.Wherefore the applicant moves that the entry upon possession of the property of Gérard Noiin Ltée be acknowledged, under the terms and conditions of the trust deeds dated May 16, 1972 and May 29, 1974 referred to hereinabove, and according to law; that the permits held by Gérard Noiin Ltée be transferred to the trustee in its capacity, and that the latter be authorized to carry on the operation of the property it now holds, in compliance with said permits; the foreging, according to law, for the benefit of the creditors, conformably to their respective preference and to other conditions which it may please the Tribunal to impose.Transport permit 15957-V reads as follows: (a) Restricted trucking - long distance -restricted route - (a) From Montreal to Québec City and within a radius of one hundred (100) miles from said City, except in the Provincial Electoral Districts of Chicoutimi, Jonquière, Kénogami, Lac-Saint-Jean, Roberval and the District of Chibougamau.(6) Restricted trucking - long distance -restricted route - (6) From Montreal to all points in the Province of Québec located east of Québec City, except in the Provincial Electoral Districts of Lac-SaintrJean, Roberval, Jonquière, Kénogami and Chicoutimi.Restriction : In the case of clauses a and b, for the transport of oil for asphalt, and of liquid 3760 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 phalte et d'asphalte liquide (Hants hydro carbonnés) pour les plana d'asphalte (béton bitumeux) en général.c) Transport restreint - longue distance -rayon- .c) De Québec à, tous les points situés dans un rayon de cent (100) milles des limites de ladite ville, sauf les districts électoraux provinciaux de Chicoutimi, Jonquière, Kénogami, Lac-St-Jean, Roberval et le district de Chibougamau.d) Transport restreint - longue distance -route restreinte - d) De Québec à tous les points situes a 1 est de la ville de Québec (sur les deux rives du St-Laurent).sauf les district électoraux provinciaux de Lac-St-Jean, Roberval, Jonquière, Kénogami et Chicoutimi.e) Transport restreint - longue distance -route restreinte - citerne - e) De Sept-Iles à Moisie, Port-Cartier, Godbout, Baie-Comeau, les Escoumains, La-brieville.Forent ville et Tadoussac et tous les points intermédiaires entre ces divers endroits pour le transport, par camions citernes, d'asphalte liquide (liants hydro carbonnés).Restriction : Dans le cas des clauses c, d et e, pour le transport, par camions citernes, d'asphalte liquide (liants hydro carbonnés)./) Transport restreint - longue distance -route restreinte - citerne - /) De Sorel à Québec et dans un rayon de cent (100) milles de ladite ville.g) Transport restreint - longue distance -rayon - citerne - g) De Sorel et de Québec à tous points situés dans la province de Québec a l'est de la ville de Québec (sur les deux rives du St-Laurent).h) Transport restreint - longue distance -route restreinte - citerne - h) De Québec à tous points situés dans un rayon de cent (100) milles de ladite ville, pour le transport de chlorure de calcium ou de calcium liquide, par camion citerne.Restriction : Dans le cas des clauses /, g et A, pour le transport par citerne, de chlorure de calcium ou de calcium liquide.t) Transport restreint - longue distance -rayon - citerne - De Rimouski à tous les endroits dans un rayon de deux cent soixante (260) milles de ladite ville, et retour, pour le transport de produits pétrolifères, par citerne.j) Transport restreint - longue distance -route restreinte - ;) De tous les endroits situés dans les comtés de Rivière-du-Loup, Kamouraska, Témis-couata et Lévis à la frontière Québec-États-Unis (tous les ports d'entrée), pour le transport de tourbe et d'humus « peat moss » (marchandise exempte des règlements de ]'Inlcretale Commerce Commission) destinés aux états du Maine, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland et le district de Columbia, pour le public en général.k) Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - citerne \u2014 *¦) De Montréal, Sorel et Québec à tous les points situés dans la province de Québec, pour le transport de calcium liquide, par camion citerne, pour le compte de Allied asphalt (hydrocarbon binders) for MP^t (asphaltic concrete) plants in general, Dy tank truck.(ç) Restricted trucking - long distance -radius - ., .(c) From Québec City to all points located within a radius of one hundred (100) miles from the limits of said City, except in the Provincial Electoral Districts of Chicoutimi, Jonquière, Kénogami, Lac-Saint-Jean, Roberval and the District of Chibougamau.(d) Restricted trucking - long distance -restricted route - (d) From Québec City of all points located east of Québec City (on both shores of the St-Lawrence River), except in the Provincial Electoral Districts of Lac-Saint-Jean, Roberval, Jonquière, Kénogami and Chicoutimi.(«) Restricted trucking - long distance -restricted route - tank - («) From Sept-Iles to Moisie, Port-Car-tier.Godboua, Baie-Comeau, Les Escoumains, Labrieville, Forestville and Tadoussac and all intermediate points between these various localities, for the transport of liquid asphalt (hydrocarbon binders) by tank truck.Restriction: In the case of clauses c, d and f, for the transport of liquid asphalt (hydrocarbon binders) by tank truck.(/) Restricted trucking - long distance -restricted route - tank - (J) From Sorel to Québec City and within a radius of one hundred (100) miles from said City.(o) Restricted trucking - long distance -radius - tank - (0) From Sorel and Québec City to all points located in the Province of Québec, east of Québec City (on both shores of the St-Lawrence River).(A) Restricted trucking - long distance -restricted route - tank - (A) From Québec City to all points located within a radius of one hundred (100) miles from said City, for the transport of calcium chloride or liquid calcium, by tank truck.Restriction : In the case of clauses /, g and A, for the transport of calcium chloride or liquid calcium.(t) Restricted trucking - long distance -radius - tank - From Rimouski to all points located within a radius of two hundred and sixty miles (260) from said City, and return, for the transport of petroleum products, by tank vehicle.(;) Restricted trucking - long distance -restricted route - (j) From all points located in the Counties of Rivière-du-Loup, Kamouraska, Témis-couata and Levis to the Quebec-United States border (all ports of entry), for the transport of peat-moss (exempt from the Regulations of the Intestate Commerce Commission) shipped to the States of Maine, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland and the District of Columbia, for the public in general.(1) Restricted trucking - long distance -radius - contract - tank - (fc) From Montreal, Sorel and Québec City to all points located in the Province of Québec, for the transport of liquid calcium, by tank truck, on behalf of Allied Chemical GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3761 Chemical Canada Ltd.et de Jean Dansereau Inc., pourvu que la détentrice en fasse l'épandage.Restriction: Les services de transport donnés à contrat pour le compte de ces deux compagnies mentionnées ci-dessus ne pourront pas être exploités sur les routes déjà couvertes par les clauses /, g et a qui autorisent le transport de calcium pour le public en général.V) Transport restreint - longue distance -rayon - citerne - l) De St-Jean-Chrysostome et de Québec à tous les endroits situés dans la province de Québec, pour le transport, par camions citernes, de gazoline, huiles légères, bunker et asphalte.Restriction : En donnant le service prévu à la clause /.la détentrice n'aura pas le droit de desservir la ville de Montréal.m) Transport restreint - longue distance -route restreinte - citerne - m) De Gaspé à Rimosuki et les points intermédiaires, et retour, pour le transport, par camion citerne, de produits pétroliers.n) Transport restreint - longue distance -route restreinte - citerne - n) De Québec, St-Jean-Chrysostome et Rimouski à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick (tous les ports d'entrée), pour le transport, par camion citerne, de gazoline, huile légère pour le public en général.Restriction: Ce service ne sera opéré que conjointement avec un permis complémentaire de la Motor Carrier Board du Nouveau-Brunswick devant être déposé à la Commission d'ici le 30 juin 1973.o) Transport restreint - longue distance -territoire - citerne - o) De tous endroits à tous endroits situés à l'est des districts électoraux provinciaux de Rivière-du-Loup et Témiscouata, ces deux derniers endroits inclus, sur la rive sud seulement pour le transport, par camion citerne, d'huile légère, gazoline et bunker.p) Transport restreint - longue distance -route restreinte - citerne - p) De Québec et de St-Romuald à la frontière Québec-Etats-Unis (tous les ports d'entrée), pour le transport, par véhicule citerne, d'asphalte liquide destinée aux états du Maine, Vermont, New Hampshire et New York, pour le public en général.Condition re / clause p: Le service autorisé par la clause ci-dessus devra être opéré conjointement avec un permis connexe à être obtenu des autorités de V Interstate Commerce Commission et dont copie devra être déposée à la Commission des transports du Québec avant le 31 janvier 1974.q) Transport restreint- contrat -q) Pour le remorquage de maisons mobiles, pour le compte de Perron Transport Ltée, détentrice du permis no 15239-V, conformément aux services autorisés par les clauses ;', *:, n et o dudit permis no 15239-V.Droit additionnel: En donnant les services autorisés par son permis, la détentrice est autorisée à utiliser le service du traversier opérant entre Matane et Godbout et Baie-Comeau.r) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - Canada Ltd.and of Jean Dansereau Inc.provided that the holder also effect the spreading of the calcium carried.Restriction : The transport service provided under contract on behalf of the two Companies hereinabove mentioned shall not be operated on Highways already covered by clauses /.g and h, which authorize the transport of calcium for the public in general.U) Restricted trucking - long distance -radius - tank - (f) From SWean-Chrysostome and Quebec City to all points located in the Province of Québec, for the transport of gasoline, light oil, bunjer and asphalt, by tank truck.Restriction : When providing a service under clause (, the holder shall not be authorized to Berve the City of Montreal.(m) Restricted trucking - long distance -restricted route - tank - (m) From Gaspé to Rimouski and all intermediate points, and return, for the transport of petroleum products by tank truck.(n) Restricted trucking - long distance -restricted route - tank - (n) From Quebec City, St-Jean-Chrysostome and Rimouski to the New Brunswick-Quebec border (all ports of entry), for the transport of gasoline and light oil, by tank truck, for the general public.Restriction : This service shall be operated only in conjunction with a complementary permit issued by the Motor Carrier Board of New Brunswick, which shall be 61ed with the Commission before June 30, 1973.(o) Restricted trucking - long distance -territory - tank - (o) From all points to any point located east of the provincial and Electoral Districts of Rivière-du-Loup and Témiscouata, including said two districts, on the south shore only, for the transport of light oil, gasoline and bunker, by tank truck.(p) Restricted trucking - long distance -restricted route - tank - (p) From Québec City and St-Romuald to the Quebec-United States border (all ports of entry), for the transport, by tank truck, of liquid asphalt shipped to the States of Maine, Vermont.New Hampshire and New York, for the public in general.Condition re / Clause p: The service authorized under the aforesaid clause shall be operated in conjunction with a related permit to be issued by the authorities of the Interstate Commerce Commission, which shall be filed with the Québec Transport Commission before January 31, 1974.(o) Restricted trucking - contract -(o) For the haulage of mobile homes on behalf of Perron Transport Ltée, holder of permit No.15239-V, in conformity with the services authorized under clauses;, k, n and o of said permit No.15239-V.Additional right: When providing the services authorized by its permit, the holder shall be authorized to use the ferry service operating between Matane.Godbout and Baie-Comeau.(r) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - 3762 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 r) De Charny au port de Québec, pour le transport, par camion citerne, de graisse animale « tallow i> pour le compte de Alex.Couture Inc.\u2022) Transport restreint - longue distance -roure restreinte - contrat - citerne - ) De Louiseville à la frontière Québec-Etats-Unis (ports d'entrée situés dans les états de New York et du Vermont), et retour avec marchandise refusée ou avariée - destination ou origine: Albany et New York, N.Y., Boston.Mass., Chicago, 111., pour le transport de meubles neufs t non peints » pour le compte de Les Meubles du Lac St-Pierre Inc., de Louiseville.Conditions et restrictions applicables à la clause m: 1.La clause m est reliée à l'autorisation accordée à Alliance Petroleum Ltée de louer ses remorques à Paul Lessard pour effectuer les services de transport autorisés par ladite clause m de son permis.(o) Cancelled as per the order dated February 11, 1972., .(o) Cancelled as per the order dated February 11, 1972.(p) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract \u2014 (p) From Louiseville and Montreal to the Quebec-United States border (ports of entry: Champlain and Rouses Point), for the transport of caaeinate.dried milk, proteins and by-products of milk, in bags, on behalf of Montreal Casein Co.Limited-destination: Champlain, Rouses Point and Ogdenburg, N.Y.U.S.A.Restriction re / Clause p: The service authorized by clause of this permit shall be operated exclusively with the complementary Interstate Commerce Commission certificate bearing the number MC-132368 sub.dated November 7, 1969.(q) Cancelled as per the order dated October 20, 1972.(o) Cancelled as per the order dated October 20, 1972.(r) Restricted trucking - long distance -territory - contract \u2014 (r) From any point to any other point within a radius of two hundred (200) miles from Louiseville, for the transport of milk and of its liquid by-products in bulk by tank truck, on behalf of La Crémerie Ayotte Inc., La Coopérative Agricole de Granby.Montreal Casein Co.Ltd., Les Produits Laitiers Baribeau Ltée and La Crémerie St-Grégoire.(«) Cancelled as per the decision rendered on January 22, 1974.(«) Cancelled as per the decision rendered on January 22, 1974.(0 Restricted trucking - long distance -radius - contract - (() From Louiseville to all localities in the Province of Québec, for the transport of new unpainted furniture, and return with refused or damaged goods, on behalf of Les Meubles du Lac St-Pierre Inc., of Louiseville.(u) Restricted trucking - restricted route -contract - (u) From Louiseville to the Québec-Ontario border (ports of entry: Pointe-Fortune and Rivière-Beaudette) and return with refused or damaged goods - destination or origin: Ottawa, Toronto, Windsor, Hamilton and London, Ont., for the transport of new unpainted pieces of furniture, on behalf of Les Meubles du Lac St-Pierre Inc., of Louiseville.(») Restricted trucking - restricted route -contract - (v) From Louiseville to the Quebec-United States border (ports of entry' located in the states of New York and Vermont), and return with refused or damaged goods - destination or origin: Albany and New York, N.Y., Boston, Mass., Chicago, 111., for the transport of new unpainted pieces of furniture on behalf of Les Meubles du Lac St-Pierre Inc., of Louiseville.Conditions and restrictions applicable to clause m: 1.Clause m is related to the authorization granted to Alliance Petroleum Ltée for the leasing of its trailers to Paul Lessard so that û ma^ C™\"0!6 the transport services authorized by said clause m of his permit. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3777 2.Des taux spécifiques s'appliqueront aux services autorisés et devront être déposés en duplicata par le détenteur conformément aux règlements de la Commission.3.Des polices d'assurance, pour dommages à autrui, à la propriété et à la marchandise devront être maintenues en vigueur par le détenteur durant l'existence du permis pour toutes les remorques louées de/et appartenant à Alliance Petroleum Ltée, permis no 53-DYL.4.Durant la période au cours de laquelle lesdits véhicules seront utilisés pour effectuer les services autorisés, le détenteur devra y apposer des marques d'identification amovibles portant son numéro de série.Ces marques d'identification devront être enlevées lorsqu'il retournera les véhicules au propriétaire.De telles marques d'identification devront montrer par lettres d'au moins deux pouces de hauteur que le véhicule est utilisé par le détenteur de permis et devront être apposées de chaque côté du véhicule.5.Le détenteur devra faire l'inspection du véhicule pour vérifier si le camion ou la remorque qui lui est transféré est en bonne condition.6.A compter du moment de l'acceptation du véhicule, le détenteur en aura la possession et le contrôle exclusifs et en assumera l'entière responsabilité.7.Le détenteur devra se servir desdits véhicules en employant ses propres chauffeurs et son propre équipement.8.Le détenteur pourra utiliser toute remorque appartenant à Alliance Petroleum Ltée pourvu que ces véhicules soient enregistrés à la Commission sur la formule RT-33 qui indiquera le nom du propriétaire et le numéro de la plaque émise par la province.9.La Commission émettra un cetificat et une plaque; cette plaque devra être apposée au véhicule dès le début de son utilisation et sera enlevée après que l'opération aura été terminée.10.Le chauffeur devra avoir en sa possession, en tout temps, le certificat de la Commission portant le numéro de la plaque émise par la Commission au nom du détenteur ainsi qu'une copie photostatée du présent permis.io) Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - w) De Louiseville à toutes les localités situées dans un rayon de 200 milles de ladite municipalité et retour, pour le transport lourd par fardier, pour le compte de Louiseville Entreprise Générale Enrg.Conditions au transport de marchandises lourdes: a) Dans tous les cas pour le transport d'objets et de marchandises qui, à cause de leur nature, grosseur, pesanteur ou forme, ne peuvent être transportés qu'à l'aide d'équipement spécial, tel que fardier, ainsi que les pièces s'y rattachant, du matériel et de l'équipement d'entrepreneur et de fourniture dont le transport se rattache au transport desdits objets ou marchandises.b) Dans tous les cas de transport effectué en vertu de ce permis, il incombera au détenteur de démontrer à la satisfaction de la Commission que les objets ou marchandises qu'il transportera ainsi ne peuvent-normalement être transportés par un détenteur de permis de camionnage général et que ce dernier ne fournit pas habituellement l'équipement que ces transports requièrent.2.Specific rates shall apply to the services authorized and shall be filed in duplicate by the holder, in conformity with the regulations of the Commission.3.Insurances policies covering damages to other persons, property and goods shall be maintained in effect by the holder throughout the validity of the permit for all trailers rented from/and belonging to Alliance Petroleum Ltée, permit No.53-DYL.4.The holder shall affix to each vehicle removable identification markers bearing its serial number, during the period throughout which said vehicles are utilized to provide the authorized services.These identification markers shall be removed when the vehicles are returned to their owner.Such identification markers shall indicate, in letters at least two inches high, that the vehicle is being utilized by the permit-holder and shall be affixed on either side of the vehicle.5.The holder shall inspect the vehicle in order to ensure that the truck or trailer transferred to him is in good condition.6.From the time of acceptance of the vehicle, the holder shall have exclusive possession and control of the vehicle and shall assume full responsibility therefor.7.When using said vehicles, the holder shall employ his own drivers and use his own equipment.8.The holder may use any trailer belonging to Alliance Petroleum Ltée provided that these vehicles be registered with the Commission on form RT-33 which shall indicate the owner's name and the number of the plate issued by the Province.9.The Commission will issue a certificate and a plate; this plate shall be attached to the vehicle from the beginning of its use and shall be removed when the operation is completed.10.The driver shall have in his possession, at all times, the certificate issued by the Commission, bearing the number of the plate issued by the Commission in the name of the holder, as well as a photostat copy of the present permit.(u>) Restricted trucking - long distance -radius - contract - (u>) From Louiseville to all the localities situated within a radius of 200 miles from said Municipality and return, for heavy transport by float, on behalf of Louiseville Entreprise Générale Enrg.Conditions applicable to the transport of heavy goods: (a) In all cases, for the transport of objects and items which, because of their nature, size, weight or shape, can be transported only by means of special equipment, such as floats, of related parts, of contractors' material and equipment, and of supplies the transport of which is related to the transport of said objects or items.(b ) In all transport operations effected pursuant to this permit, it shall be, incumbent upon the holder to prove to the satisfaction of the Commission that the items or goods that he so transports cannot normally be transported by the holder of a general trucking permit, and that the latter does not nor.nally supply the equipment required for such transport. 3778 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Rôle Q-3510 23227-V-D-2-TF LES DÉMÉNAGEMENTS TRANS-QUÉBEC INC.570, Côte des Couture St-Louis-de-Pintendre (Lévis) (Que.) Rôle Q-3512 Q-504962-D-001 ALAIN GAGNON 151, Gamacbe Sept-Iles (Que.) Rôle Q-3513 Q-504491-D-O01 H.DROUIN & FRÈRES LTÉE 224, rue St-Pierre Ste-Agathe (Lotbinière) (Que.) Rôle Q-3514 Q-504491-D-002 H.DROUIN & FRÈRES LTÉE 224.rue St-Pierre Ste-Agathe (Lotbinière) (Que.) Rôle Q-3515 69-V-D-3 BOURRET TRANSPORT I Et.R.R.4 Drummondville (Que.) c) Pour donner le service autorisé ci-dessus, (c) In order to provide the service herein-le détenteur devra utiliser les fardiers appar- above authorized, the holder shall use the tenant à Louiseville Entreprise Générale floats belonging to Louiseville Entreprise Enrg.lesdits fardiers étant enregistrés à la Générale Enrg.said floats being registered province par ledit expéditeur Louiseville in the Province by the said shipper, Louise-Entreprise Générale Enrg.ville Entreprise Générale Enrg.Les conditions habituelles à ce genre de The regular conditions applicable to this permis s'appliquent, tout particulièrement type of permit shall apply, more particularly les dispositions prévues par l'article 13d de the provisions of article 13d of the General l'Ordonnance générale sur le camionnage.Order on trucking.Les actions de Transport Paul Lessard Inc.The shares of Transport Paul Lessard Inc., se répartissent comme suit: are distributed as follows: Actions Common ordinaires shares M.Paul Lessard, prés.798 Mr Paul Lessard près.798 M.Serge Lessard, vice-prés.1 Mr Serge Lessard, vice-pres.Mme Jacqueline Lessard, secr.1 Mrs.Jacqueline Lessard, secr.1 La requérante demande à la Commission The applicant requests from the Québec des transports du Québec l'autorisation Transport Commission authorization to in- d'augmenter ses tarifs pour le déménagement crease its tariffs for local moving in Québec local pour Québec et banlieue, pour qu'ils City and suburbs, so that they read hence- se lisent à l'avenir comme suit: forth as follows: Tarif à l'heure du lundi au vendredi de Hourly tariff from Monday to Friday 08:00 à 17:30 heures: from 8:00 o'clock a.m.to 5:30 o'clock p.m.: l'heure l'heure per hour 1 camion avec chauffeur / / truck with driver.S18 1 camion avec 2 hommes /1 truck with 2 men.26 1 camion avec 3 hommes / / truck with S men.34 1 camion avec 4 hommes / I truck with 4 men.42 Aide additionnel / Additional help.8 Service de contremaître / Foreman service.12 Charge supplémentaire pour usage d'un fourgon excédant 35' de longueur / Additional charge for the use of a van exceeding Sô' in lenght.5 Le temps et demi est calculé après les Time-and-a-half rates shall apply after the heures ci-haut mentionnées ainsi que le hours hereinabove mentioned, and on Satur- samedi.days.Pour le tarif concernant les supplémen- For the tariff respecting overtime, the \u2022 aires, lea conditions sont telles que stipulées conditions are those prescribed by Order dans l'ordonnance 5677.5677.Le requérant demande un permis de ca- The applicant requests a bulk trucking mionnage en vrac, de catégorie Artisan, pour permit.Artisan class, for Region No.9.la région no 9.Le requérant, qui possédait un camion au 14 avril 1972, demande un permis de camionnage en vrac, de catégorie Entrepreneur, pour le transport de bois pulpe, bois de sciage, etc, pour la région no 3.requérant, qui possédait un camion au 14 avril 1972, demande un permis de camionnage en vrac, pour le transport de bois pulpe, bois de sciage, etc, de catégorie Entrepreneur pour la région no 3.Modification de permis: La partie requérante demande l'autorisation de donner le service de transport suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - De Drummondville à Knowlton et retour avec marchandises refusées ou endommagées, pour le transport de marchandises provenant de Imco Container Canada Limited.The applicant which has owned a truck since April 14, 1972, requests a bulk trucking permit.Contractor class, for the transport of pulpwood, sawn timber, etc., for Region No.3.The applicant, who has hold a truck since April 14, 1972.requests a bulk trucking permit, for the transport of pulpwood, sawn timber, etc., Contractor class, for Region No.3.Modification of permit: The applicant requests authorization to provide the following transport service: Restricted trucking - long distance -restricted route - From Drummondville to Knowlton, for the transport of goods originating from Imco Container Canada Limited, and return with refused or spoilt goods. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1975.107- année, n' 19 3779 Rôle Q-3516 3255-A-D-2 3255-A AUTOCARS FOURNIER INC.2200.Lavoisier St«-Foy (Que.) et/and 3640-A AUTOCARS G.C.INC.4543.boul.Talbot Chicoutimi (Que.) Rôle Q-3517 3248-A-D-l 3248-A JEAN-CLAUDE ROY R.R.no 1 Kingsey Falla (Drummond) (Que.) et/and CILLES BOLDUC GARAGISTE R.R.no 1 Kingsey Falls (Drummond) (Que.) Rôle Q-3518 8448-V-D-7 GLENGARRY TRANSPORT (QUEBEC) LTÉE GLENGARRY TRANSPORT (QUÉBEC* LTD.2350, boul.des RécolleU CP.872 Trois-Rivières (Que.) Rôle Q-3519 Q-502999-D-005 TREMBLAY, GEORGES 3024, boul.Ste-Geneviève Chicoutimi-Nord (Que.) Demande de transfert: Autocars Fournier Inc.demande à la Commission des transports du Québeo de transférer à Autocars G.G.Inc.les services no 1 et no 6 qu'elle détient actuellement par le permis 3255-A.Service no 1 : De Dolbeau à St-Joseph-d'Alma et retour et les points intermédiaires suivants: ville de Mistassini, paroisse St-Michel-de-Mistas-sini.Ste-Jeanne-d'Arc, Péribonka, Ste-Moni-que-de-Honfleur.St-Henri-de-Taillon.8t-Coeur-de-Marie, Canton Delisle, Ile-Maligne et village de Naudville.Parcours à suivre: Route 55 de Dolbeau à St-Joseph-d'Alma.Conditions et restrictions: a) pas de service local entre Dolbeau et la ville de Mistassini, ces deux endroits inclus, b) pas de service local entre Ile-Maligne et la ville de St-Joseph-d'Alma, ces deux endroits inclus.Service no 6: De Kénogami à Dolbeau et retour.Parcours à suivre: Dans Kénogami: rue 8te-Famille Dans Jonquière : rue St-Dominique Route no 16: de Kénogami à St-Brunu Route no 55: de St-Bruno à Dolbeau.Conditions et restrictions: a) pas de service local entre Kénogami et Jonquière, ces deux endroits inclus.b) pas de service local dans les limites de la ville de Roberval, c) ce service n'affecte en rien les droits concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie que peut présentement posséder tout autre détenteur.Demande de transfert: Le requérant-vendeur Jean-Claude Roy, R.R.no 1, Kingsey Falls, Drummond.demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation de vendre à Gilles Bolduc Garagiste, R.R.no 1, Kingsey Falls.Drummond, son permis de transport 3248-A qu'il détient qui se lit comme suit: Transport de personnes de Kingsey Falls, Kingsey station (Nicolet Fall) à Asbestos aller et retour 3 fois par jour et 6 jours par semaine avec autobus 12 passagers maximum.Modification de permis: La requérante demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation de donner le service suivant: Transport restreint - longue distance -route - contrat - De Montréal à 8hawinigan, La Tuque et St-Félicien.et retour, pour le transport de marchandises pour le compte de La Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada, de gare à gare, avec le droit de donner le service entre les quatre dites gares, ainsi que le droit de cueillette et livraison de marchandises à St-Félicien, La Tuque et Shawinigan.Le requérant, qui possède l'attestation Q-502999-D-005, demande un permis de camionnage en vrac, de catégorie Entrepreneur, pour la région no 2.Application for transfer: Autocars Fournier Inc.requests the Québec Transport Commission to transfer to Autocars G.G.Inc.services No.1 and No.6 which it is presently authorized to provide according to permit 3255-A.Service No.1 : From Dolbeau to St-Joseph-d'Alma and return, and the following intermediate points : Town of Mistassini, Parish of St-Michel-de-Mistassini, Ste-Jeanne-d'Arc, Péribonka.Ste-Monique-de-Honfleur.St-Henri-de-Taillon.St-Coeur-de-Marie.Township of Delisle, Ile-Maligne and Village of Naudville.Route: Highway 55 from Dolbeau to St-Joseph-d'Alma.Conditions and restrictions: (a) No local service between Dolbeau and the Town of Mistassini, including these two points.(b) No local service between Ile-Maligne and the Municipality of St-Joseph-d'Alma.including these two points.Service No.6: From Kénogami to Dolbeau and return : Route: In Kénogami: Ste-Famille Street In Jonquière : St-Dominique Street Highway No.16: From Kénogami to St-Bruno Highway No.65: From St-Bruno to Dolbeau.Conditions and restrictions: (a) No local service between Kénogami and Jonquière, including these two points; (b) No local service within the limits of the City of Roberval; (c) This service affects in no way the rights which any other holder may presently have concerning special or charter trips.Application for transfer: The applicant-vendor Jean-Claude Roy, R.R.No.1, Kingsey Falls, Drummond.requests from the Québec Transport Commission authorization to sell to Gilles Bolduc, garage keeper, R.R.No.1, Kingsey Falls, Drummond, his transport permit No.3248-A which reads as follows: Transport of persons from Kingsey Falls, Kingsey station (Nicolet Fail) to Asbestos, and return, three times a day, six days a week, utilizing a bus of a maximum capacity of 12 passengers.Modification of permit: The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following service: Restricted trucking - long distance -route - contract - From Montreal to Shawinigan, La Tuque and St-Félicien, and return, for the transport of goods on behalf of the Canadian National Railways, from station to station with the right to provide a service between the four said stations, as well as the right to pick up and delivery goods in St-Félicien, La Tuque and Shawinigan.The applicant, who holds certificate Q-502999-D-005, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for Region No.2. 3780 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, Map 10, 1976, Vol.107.No.19 Rôle Q-3520 Q-200984-D-2 ROMÉO GUILLEMETTE Rue Principale St-Raphael (BeUechasse) (Que.) Rôle Q-3521 23474-V-D-3 BUJOLD, JULIEN 26, rue du Rallye Rimouski (Que.) Rôle M-8150 1417-V-D-3 TRANS-ILE INC.673.Bellevue sud Greenfield Park (Que.) Le requérant demande à la Commission un permis de transport par véhicule-taxi pour desservir les municipalités de St-Raphaél village, St-Raphaël paroisse, Armagh village, St-Cajetan-d' Armagh, St-Nérée et St-Gervais.Modification de permis: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation de donner le service de transport suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - D'Amqui, Rimouski, Bic et Trois-Pistoles à Sept-Iles, via les services de traversiez opérant entre la rive-sud et la rive-nord du fleuve St-Laurent ou via Québec, et à St-Romuald-d'Etchemin et Montréal, et retour, pour le transport, inter-usines, de lait en vrac et de marchandises en général, par véhicules ordinaires ou citernes, pour le compte de La Coopérative Agricole du Bas St-Laurent.Restriction : En donnant le service précité, le détenteur ne devra utiliser que des véhicules ordinaires ou citernes appartenant à et loués de La Coopérative Agricole du Bas St-Laurent, pour le transport de lait en vrac et de toutes marchandises provenant de ou destinées à ladite Coopérative et pour le compte de cette dernière.Transfert d'actions: MM.Martin Barth & Eric Claus Requérant-vendeurs Price Wilson Limited-Limitée 63.rue Ste-Anne Québec (Que.) G1R 3X5 Requérante-acquéreur.Les requérants-vendeurs se sont adressés à la Commission des transports, dans le but d'obtenir Bon approbation de la vente et du transfert de toutes les actions ordinaires émises par la compagnie mise en cause, en faveur de la requérante-acquéreur.On demande de ce faire, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi des transports du Québec.Distribution présente: Action» ordinaires Martin Barth.499 Eric Claus.499 Karin Barth.2 Distribution future: (de la mise en cause Price Wilson Limited.997 Price Wilson Limitée J.R.Cunnane.1 C.D.Robertson.1 J.Leboutillier.1 Les actions de Price Wilson Limited-Limitée, la partie qui contrôle les actions de la mise en cause, sont distribuées comme suit: Actions La Compagnie Price Limitée.165,747 J.R.Cunnane.i K.I.Gordon.\\ A.A.Labrecque.i The applicant requests from the Commission a permit to effect transport by taxi-caD in the Municipalities of St-RaphaJH \\ Ulage.St-Raphael Parish.Armagh ,>'lla?*' °y Cajetan-d'Armagh, St-Nérée and St-Gervais.Modification of permit: The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following transport service: Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - From Amqui, Rimouski, Bic and Trois-Pistoles to Sept-Iles, via the ferry services operating between the south shore and the north shore of the St.Lawrence River or via Québec City, and to St-Romuald-d'Etche-min and Montreal, and return, for the inter-plant transport of bulk milk and general goods, by standard or tank vehicle, on behalf of La Cooperative Agricole du Bas St-Lau-rent.Restriction : When providing the aforesaid service, the holder shall utilize ordinary or tank vehicles belonging to and leased from the Cooperative Agricole du Bas St-Laurent, for the transport of bulk milk and goods from or to said Cooperative, and of behalf of the latter.Transfer of shares: Messrs.Martin Barth 4 Eric Claus Applicant-vendors Price Wilson Limited 63 St.Anne Street Québec.P.Q., G1R 3X5 Applicant-purchaser.The applicant-vendors request from the Transport Commission approval of the sale and transfer of all common shares issued by the company mise en cause in behalf of the applicant-purchaser.This request is made in conformity with the provisions of section 39 of the Québec Transport Act.Present distribution: Common shares Martin Barth.49g Eric Claus.499 Karin Barth.2 Future distribution: (of the mite en cause) Price Wilson Limited.997 J.R.Cunnane.1 C.D.Robertson.1 J.Leboutillier.,, 1 The shares of Price Wilson Limited, the party which controls the shares of the miss en cause, are alloted as follows: Shares La Compagnie Price Limitée____ 166,747 J.R.Cunnane.j K.I.Gordon.A.A.Labrecque. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3781 Rôle M-8151 17446-V-D-2 G.COMTOIS TRANSPORT ENRG.M.Stephen H.Miller ès-qualité de syndic à la faillite de / in his capacity as trustee in the bankruptcy of: (Gilles Comtois opérant sous ce nom / operating under this name :) 6981, Chateaubriand Montréal 328 (Que.) Rôle M-8173 30006-D-43-TF NIAGARA FRONTIER TARIFF BUREAU, INC.(Membres participants de / Participating Members of the) P.O.Box 184 Buffalo, N.Y.14221 Rôle M-8175 21015-V-D-l J.E.MARTINEAU Barnston (Stanstead) (Que.) Transfert de permis à : Transport J.M.R.Ltée 1400.rue Marie-Claire LaSalle-Lachine 660 (Que.) Requérante-acquéreur.Le requérant-vendeur, avec l'assentiment du syndic à la faillite, M.Stephen Miller, demande à la Commission des transports d'approuver le transfert de son permis, en faveur de la partie requérante-acquéreur.On demande de ce faire, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi des transports.Les actions de Transport J.M.R.Ltée, la requérante-acquéreur, sont distribuées comme suit: Actions ordinaire» M.Jean Roy.2 M.Marcel Roy.2 M.René Roy.2 Les services autorisés par le permis 17446-V sont les suivants: a) Transport général - Service local - a) Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (6) milles des limites de ladite ville.b) Transport général - longue distance -rayon - b) De Montréal à tous les endroits situés dans un rayon de trente (30) milles des limites de ladite cité, et retour.Demande de fixation de tarif: Tarif 220 (Papier tariff) Item: 4145 (Addition) 4160 (Addition) 4155 (Addition) 4170 (Addition) 4200 (Addition) 4265 (Addition) 4260 (Addition) 4280 (Addition) 4326 (Addition) 4330 (Addition) Supplément 27 au tarif 261-D (marchandises générales) Item: 9320-A (Addition) 1042 (Change) 11385 (Addition) Supplément 50 au tarif 270-C (Tarif de fer et d'acier) Item: 8613 (Addition) 8517 (Addition) 8577 (Addition) Supplément 6 au tarif 368-A (Tarif de classe et marchandise) Item: 10660-A (Addition) Pour obtenir des renseignements complémentaires veuillez consulter lesdits suppléments déposés auprès de la Commission des transports du Québec.Transfert de permis: Le requérant-vendeur: J.E.Martineau Barnston (8tanstead) (Que.) s'adresse à la Commission des transports du Québec dans le but d'obtenir l'approbation de cette dernière, sur le transfert de son permis 21016-V en faveur du: Transfer of permit to: J.M.R.Transport Ltd.1400 Marie-Claire Street LaSalle, P.Q.H8N 1R9 Applicant-purchaser.The applicant-vendor, with the consent of the trustee in the bankruptcy, Mr Stephen Miller, requests from the Transport Commission approval of the transfer of his permit in behalf of the applicant-purchaser.This request is made in conformity with the provisions of section 36 of the Transport Act.The shares of J.M.R.Transport Ltd., the applicant-purchaser, are alloted as follows: Common shares Mr Jean Roy.2 Mr Marcel Roy.2 Mr René Roy.2 Permit 17446-V authorizes the following services: (a) General trucking - local service - (a) Montreal and all points located within a distance of five (5) miles from the limits of said City; (b) General trucking - long distance - radius - (b) From Montreal to all points located within a radius of thirty (30) miles from the limits of said City, and return.Application for fixation of tariff : Tariff 200 (Newsprint tariff) Item: 4145 (Addition) 4160 (Addition) 4155 (Addition) 4170 (Addition) 4200 (Addition) 4255 (Addition) 4260 (Addition) 4280 (Addition) 4325 (Addition) 4330 (Addition) Supplement 27 to tariff 261-D (General commodity tariff) Item: 9320-A (Addition) 1042 (Change) 11385 (Addition) Supplement 50 to tariff 270-C (Iron and steel tariff) Item: 8513 (Addition) 8617 (Addition) 8577 (Addition) Supplement 5 to tariff 368-A (Class and commodity tariff) Item: 10660-A (Addition) For further information please refer to these supplements filed with the Québec Transport Commission.Transfer of permit: The applicant-vendor: J.E.Martineau Barneton (Stanstead) (Que.) requests from the Québec Transport Commission approval of the transfer of his permit 21016-V in behalf of: 3782 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975.Vol.107, No.19 Requérant-acquéreur: Bernard Martineau 66, rue Thornton, app.2 Coaticook (Que.) Le tout conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi des transports.Teneur du permis 21015-V: a) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - a) De Rivière-du-Loup à la frontière Québec-Etats-Unis (port d'entrée: Stanhope) pour le transport de tourbe « peat moss » (marchandise exempte des règlements de Vlnterttate Commerce Commission) destinée aux états de la Nouvelle-Angleterre, pour le compte de Napoléon Lafaille, de Coaticook (Que.).6) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - b) De Rivière-du-Loup et de tous les points situés dans un rayon de trente (30) milles de ladite ville, aux frontières Québec-Etats-Unis (tous les ports d'entrée), pour le transport de mousse en tourbe \"peat moss\" destinée aux états de la Nouvelle-Angleterre, Connecticut, New-York.New Jersey, Pennsylvania, pour le compte de Beaver Peat Moss Co.De plus, par la même occasion, le requérant demande que les deux clauses soient à contrat pour Beaver Peat Moss Co., vu que le contrat indiqué, à la clause a est au nom de Napoléon Lafaille qui est le propriétaire de Beaver Peat Moss Co.Le tout dans le but de corriger la teneur du permis 21016-V et de rétablir les faits.Rôle M-8323 30004-D-92-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS.1434, Ste-Catherine, suit 404 Montréal (Que.) Rôle M-8326 30003-D-74-TF BUREAU DES TARIFS DU QUÉBEC INC.1259, rue Berri, suite 460 Montréal (Que.) Demande d'augmentation de 8% applicable aux taux et frais minimums (mais non aux frais accessoires) figurant aux tarifs ci-dessous; cette augmentation entrera en vigueur le 2 juin 1975, suivant la procédure décrite à l'article 2.58.1 du Règlement 2H concernant les règles de pratique de la Commission des transports.Demande est faite de publier cet avis incessamment dans la Gazette officielle du Québec, vu la période d'attente de 21 jours après la première publication qui s'applique dans le cas présent.Tarif de marchandises no 1005-E entre Québec et l'Ouest du Canada, C.T.Q.no 4098.Taux applicables au transport à destination de l'Ouest seulement: ces taux sont énumérés à la sect.on 1 (exception: l'item 1190) et à la section Importation et Exportation.Tarif de classe et de marchandises de tous genres no 1030-B applicable entre Québec et l'Ouest du Canada, C.T.Q.no 4097.Taux dans la section 3, section 4, section 5 et section 6.Demande de fixation de taux: Tarif 120 Québec-Provinces Atlantiques.Règlement no 86.Nouveau règlement: « Marchandise d'une valeur extraordinaire.» Note: Pour renseignements supplémentaires, veuillez consulter les demandes déposées à la Commission des transports du Québec.The applicant-purchaser: Bernard Martineau 66 Thornton St.Apt.2 Coaticook (Que.) ., The whole in conformity with the provisions of section 36 of the Transport Act.Terms of permit 21015-V: (a) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (a) From Rivière-du-Loup to the Quebec -United States border (port of entry: Stanhope) for the transport of peat moss (merchandise exempt from regulations of the Interstate Commerce Commission) destined for the New England States, on behalf of Napoléon Lafaille of Coaticook (Que.) (b) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract \u2014 (b) From Rivière-du-Loup and all points located within a radius of thirty (30) miles from said Town to the Quebec-United States border (all ports of entry) for the transport of peat moss destined for the New England States, Connecticut, New Yord, New Jersey, Pennsylvania, on behalf of Beaver Peat Moss Co.In addition, the applicant requests that the above clauses be carried out under contract for Beaver Peat Moss Co.since the contract mentioned in clause a refers to Napoléon Lafaille, owner of said company.The whole for the purpose of correcting the terms of permit 21015-V and clarifying the facts.Request increase of 8% in rates and minimum charges (but not accessorial charges) in the tariffs named below, effective June 2nd, 1975 under procedures in 2H, section 2.58.1 of Transport Commission Rules of Practice.Urgent request is made for immediate publication in the Québec Official Gazette due to the 21-day waiting period after first gazetting.Commodity Tariff No.1005-E between Québec and Western Canada.Q.T.C.No.4098.Westbound rates only in section 1 (except Item 1190) and in Export and Import section.Freight all kinds and class tariff No.1030-B between Québec and Western Canada, Q.T.C.No.4097.Rates in section 3, section 4, section 5 and section 6.Application for fixation of rates: Tatiff 120 Quebec-Atlantic-Provinces.Rule No.86.New rule : \"Extraordinary valued Goods.\" Note: For further informations, see application hied with the Québec Transport Commission. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975.107' année, n° 19 3783 Rôle M-8329 30003-D-75-TF BUREAU DES TARIFS DU QUÉBEC INC.1259, rue Berri, suite 460 Montréal (Que.) Demande de fixation de taux: Tarif 15-D Amender les frais au règlement no 280 de ce tarif.Changer le titre du règlement no 280 de ce tarif.Changer la phraséologie du premier paragraphe du règlement no 280 pour être identique au premier paragraphe du règlement no 395 au tarif 100-C.Retirer la note 4 au règlement no 280 de ce tarif.Tarif 70-B Item 741.Nouvel item.Item 220.Amender les taux aux sections à destination pour Montréal et Québec.Ajouter une note: Les taux à Montréal et Québec ne seront pas sujet à l'augmentation de juillet 10% si accordée, à moins que les taux du Chemin de Fer augmentent.Tarif 75 Item 1091.Nouvel item.Item 601.Nouvel item.Item npi.Nouvel item.Item 5178.Nouvel item.Tarif 80-A Item 4319.Ajouter: Panneaux de fibre, en ballots: à pâte de bois.Un taux de $0.38 cwt., minimum 40,000 lb.Le taux pour le rebut de papier sera amendé à 80.42 cwt.minimum 45,000 lb P.T.L.Itme 3362 Nouvel item.Item 2920.Ajouter un taux à 80.36 cwt., minimum 50,000 lb.pour Montréal seulement.Item 4310et 4312.Amender certains taux selon la demande et augmenter selon les suppléments d'augmentation no 37 et no 38 pour les autres taux.Tarif 90-A Item 915.Amender les taux.Publier des frais minimum de 89.63 pour expédition L.T.L.Tarif 100-C Règlement no 6.Ajouter à la section: Exception pour certains camionneurs.Claude Seguin Transport Inc.Ajouter aux municipalités suivantes la référence F-5: Aylmer, Chelsea, Deschênes, Gore.Ironside, Kingsmere, Lachenaia, Lakefield Lake, Lochaber, Lochaber-Nord, Bois-Briand, Lucerne, Mascouche, Pincourt, Pine Hill, Sir John Lake, Templeton, Tenaga, Touraine, Wright et Wrightville.Changer les clés de base suivantes: Notre-Dame-du-Laus - Buckingham de 40 à 46.Notre-Dame-du-Laus - Papineauville de 70 à 57.Val-des-Bois - Buckingham de 40 à 43.Vai-des-Boi8 - Papineauville de 43 à 51.Page 370.Ajouter à la référence 5 : Bourret Transport Ltée.Tarif 101-D Cédule385.Amender les taux.Application for fixation of rates: Tariff 16-D Amend the charges to Rule No.280 of this tariff.Change the title to Rule No.280 of this tariff.Change the phraseology of the first paragraph to Rule No.280 so it will be identical to first paragraph of Rule No.395 of tariff 100-C.Withdraw the note 4 to Rule No.280 of this tariff.Tariff 70-B Item 741.New item.Item 220.Amend the rates to sections destined to Montreal and Québec.Add a note: The rates to Montreal and Québec will not be subject to July increase 10% if granted unless the Rait rates increase.Tarif 75 Item 1091.New item.Item 601.New item.Item 1701.New item.Item 5178.New item.Tariff 80-A Item 4319.Add: Fiberboard, in bales: to woodpulp.A rate of $0.38 cwt minimum 40,000 lb.The rate for scrap paper will be amended to 80.42 cwt, minimum 45,000 lb.P.T.L.Item 3362.New item.Item 2920 Add a rate of $0.35 cwt., minimum 50,000 lb.for Montreal only.Items 4310 and 4312.Amend certain rates as requested and include the increase supplements No.37 and No.38 for the other rates.Tariff 90-A.Item 915.Amend the rates.Publish minimum charge of 89.63 per shipment L.T.L.Tariff 100-C Rule No.6.Add to the section: Exception for some carriers.Claude Seguin Transport Inc.Add to the following localities the reference F-5: Aylmer, Chelsea, Deschênes, Gore, Ironside, Kingsmere, Lachenais, Lakefield Lake, Lochaber, Lochaber-Nord, Bois-Briand, Lucerne, Mascouche, Pincourt, Pine Hill, Sir John Lake, Templeton, Tenaga, Touraine, Wright and Wrightville.Change the following rate bases: Notre-Dame-du-Laus - Buckingham from 40 to 46.Notre-Dame-du-Laus - Papineauville from 70 to 57.Val-des-Bois - Buckingham from 40 to 43.Val-des-Bois - Papineauville from 43 to 51.Page 370.Add to the reference 5: Bourret Transport Ltée.Tariff 101-D Schedule 385.Amend the rates. 37S4 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1976, Vol.107, No.19 Rôle M-8330 30003- D-76-TF BUREAU DES TARIFS DU QUÉBEC INC.1259.rue Berri, suite 460 Montréal (Que.) Item 4681 - Cédule 6790.Nouvel item et cédule.Item 2601 - Cédule 2246.Nouvel item et cédule.Item 660 - Cédule 460.Ajouter les destinations suivantes: Daveluyville, Princeville, Victoriaville et Warwick.Item 6570.Ajouter à la nomenclature de la description: Graisseur, boites de coussinets pour wagon de Chemin de Fer ou locomotives.Item 1795.Nouvel item pour oxide de zinc.Tarif 120 Item 50.Ajouter St-John N.B.comme destination.Item 562.Annuler cet item.Item 6076.Nouvel item.Tarif X-105-B Item 218.Les frais distribution et manutention seront augmentés de 12.80 à $3.50.Les frais de service de protection seront augmentés de $0.67 cwt.à $1.25 cwt.Une note sera ajoutée: Applicable pour expéditions multiples reçues d'un expéditeur d'un seul endroit et d'une seule fois pour livraisons multiples d'au moins cinquante (50).Contrat à taux convenu no 1 entre Hamel Transport Ltée et Aluminium Co.of Canada Ltd.Augmentation des taux.Demande de fixation de taux: Suppléments intérim Arthur Paradis Transport Enrg.no 1855.Clause d.Annuler les taux.Lee taux publiés aux tarifs émis par le B.T.Q.s'appliqueront.Clause e.Augmenter les taux horaires et au millage.Germain Leblanc Transport no 1473.Clauses a et b.Augmenter les taux.Clauses c et d: Nouvelles clauses.Genesse Transport Inc.no 1987.Clauses a et b.Augmenter les taux horaires et au millage.Clauses d.e, i, l, q, r, a et t.Augmenter les taux.Champlain Sept-Iles Express Inc.no 1673.Clauses: d, e, k, m.n, o, p.q, r.s, u, ce.//, 00.c, h cl n.Augmenter les taux.Forget Transport Inc.no 1859.Clauses u et y.Augmenter les taux.Transport Frenette no 2064.Clause e.Publier les taux de contrat avec CP.Express.Transport Théberge Ltée no 1847.Clauses a et i.Augmenter les taux.Roy Transport no 2076.Emettre un supplément intérim à ce nouveau membre.Item 4681 - Schedule 6790.New item and schedule.Item 2601 - Schedule 2246.New item and schedule.Item 650 - Schedule 450.Add the following destinations: Daveluyville, Princeville, Victoriaville and Warwick.Item 5570.Add to the description the following: Lubricators, journal-box for Railway cars or locomotives.Item 1795.New item for oxide zinc.Tariff 120 Item 60.Add St-John N.B.as destination.Item 552.Cancel this item.Item 6076.New item.Tariff X-105-B Item 218.The distribution and handling charges will be increased from $2.80 to $3.50.The protective service charges will be increased from $0.67 cwt to $1.25 cwt.Add a note: Applicable on multiple shipments received from one shipper at one time at one place with multiple deliveries of not less than fifty (50).Agreed Charge No.1 Between Hamel Transport Ltée and Aluminium Co.of Canada Ltd.Increase the rates.Application for fixation of rates : Interim supplements Arthur Paradis Transport Enrg.No.1865.Clause d.Cancel the rates.Rates published in B.T.Q.tariffs will apply.Clause \u2022¦ Increase the hourly and mileage rates.Germain Leblanc Transport No.1473.Clauses a and b.Increase the rates.Clauses c and d.New clauses.Genesse Transport Inc.No.1987.Clauses a and 6.Increase the hourly and mileage rates.Clauses d, e, i, l, q, r, a and (.Increase the rates.^Champlain Sept-Iles Express Inc.No.Clauses: d, e, k, m, n, o.p, q, r, », u, cc, II, c, h et u.Increase the rates.Forget Transport Inc.No.1869.Clauses u and y.Increase the rates.Transport Frenette No.2064.Clause e.Publish the contract rates with CP.Express.Transport Théberge Ltée No.1847.Clause Q and i.Increase the rates.Roy Transport No.2076.Issue an interim supplement to this new member. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1976, 107' année, n\" 19 3785 Rôle M-8336 2975-V-D-l GÉNÉREUX TRANSPORT ENRG.(Germain Généreux opérant sous ce nom / operating under this name) 244, rue Précieux-Sang, Joliette (Que.) Rôle M-8390 1637-V-D-2 MERCIER EXPRESS INC.1, Antonio-Goyette Ste-Martine Châteauguay) (Que.) Rimouski Transport Ltée no 1828.Clauses a et ».Augmenter les taux.Clause e.Annuler les taux.Les taux publiés aux tarifs émis par le B.T.Q.s'appliqueront.Delson Transport Ltée no 1924.Clauses: a, b, c, m, », *, p, q, r, », t, u, x, z et aa.Augmenter les taux.Coaticook Express Inc.no 1967.Clause e.Augmenter les taux.Beaulieu Transport Enrg.no 1848.Clauses a, b, d et h.Augmenter les taux.Morneau Transport Enrg.no 1741.Clause/ - Contrat.Ajouter la destination suivante: St-Pascal de Kamouraska.Transfert partiel: Le requérant-vendeur.Généreux Transport Enrg.(Germain Généreux opérant sous ce nom) s'est adressé à la Commission des transports dans le but d'obtenir l'autorisation de transférer au requérant-acquéreur: Lépine, Jean 327, rue St-Charlea-Borromée Nord Joliette (Que.) J6E 4R9 la partie de son permis qui se lit comme suit: Classe: Transport restreint - par contrat - service local -Service: Joliette et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite ville, pour le transport de marchandises pour le compte de Canadian National Railway Company.On demande de ce faire, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi des transports.Transfert d'actions: Dames Michelle Lauzon, Jeannine Lauzon et M.Aldio Lauzon se sont adressés à la Commission des transports dans le but d'obtenir l'autorisarion de vendre les actions qu'ils possèdent dans la compagnie mise en cause, et qui sont les seules émises, en faveur de Thao-Go Corporation Ltd.On demande de ce faire conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi des transports._ Distribution actuelle dans Mercier Express Inc: actions ordinaires Michelle Lauzon.98 Jeannine Lauzon.1 Aldéo Lauzon.1 Advenant l'approbation du transfert des actions ordinaires de la compagnie mise en cause, à l'avenir, celles-ci seront entièrement contrôlées par Thac-Go Corporation Ltd.dont les administrateurs agiront au même titre dans la compagnie mise en cause et dont les actions émises sont distribuées comme suit: actions ordinaires Clifford W.Thacker.60 William G.Gohlke.49 Beverley G.Thacker.1 Rimouski Transport Ltée No.1828.Clauses a and »'.Increase the rates.Clause e.Cancel the rates.Rates published in B.T.Q.tariffs will apply.Delson Transport Ltée No.1924.Clauses: a, b, c, m.»', k, p, q, r, «, t, u, z, z and aa.Increase the rates.Coaticook Express inc.No.1967.Clause e.Increase the rates.Beaulieu Transport Enrg.No.1848.Clauses a, b, d and h.Increase the rates.Morneau Transport Enrg.No.1741.Clause / - Contract.Add the following destination: St-Pascal de Kamouraska.Partial transfer: The applicant-vendor, Généreux Transport Enrg.(Germain Généreux operating under this name) requests from the Québec Transport Commission authorization to transfer to the applicant-purchaser: Lépine, Jean 327 St.Charles-Borromée St.North Joliette (Que.) J6E 4R9 the part of his permit which reads as follows: Class: Restricted trucking - by contract - local service -Service : Joliette and all points located within a distance of five miles from the limits of said Town, for the transport of merchandise on behalf of Canadian National Railway Company.This request is made in conformity with the provisions of section 36 of the Transport Act.Transfer of shares: Mrs.Michelle Lauzon, Jeannine Lauzon, and Mr.Aldéo Lauzon request from the Transport Commission authorization to sell the shares they hold in the Company mise en cause, which were the only shares issued, in behalf of Thac-Go Corporation Ltd.This request is made in conformity with the provisions of section 39 of the Transport Act.Present allotment of shares in Mercier Express Inc.: common shares Michelle Lauzon.98 Jeannine Lauzon.1 Aldéo Lauzon.1 Should transfer of the common shares of the company mise en cause be approved, said shares shall be placed under the full control of Thac-Go Corporation Ltd.the directors of which shall also act as directors of the company mise en cause.The issued shares of Thac-Go Corporation Ltd.are allotted as follows: common shares Clifford W.Thacker.60 William G.Gohlke.49 Beverley G.Thacker.1 3786 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107.No.19 Le permis de la partie mise en cause se lit comme suit: a) Transport général - service local - a) Mercier et tous les endroitB situés sur une distance ne dépassant pas cinq (6) milles îles limites dudit endroit; 6) Transport général - longue distance -rayon \u2014 b) De Mercier à tous les endroits situés dans un rayon de trente (30) milles des limites dudit endroit, et retour; c) Transport général - longue distance -route restreinte - irrégulier - c) De Mercier à Valleyfield et Montréal, et retour.Restriction: En vertu des clauses a.b et c de son permis, la détentrice n'est pas autorisée à desservir la ville de St-Rémi en vertu de l'interprétation de la distance de cinq (5) mille» de son terminus de base qui est Mercier.Service à contrat: Pour le compte d'Urgel Charette Transport Ltée, selon les clauses o, b, c, d.e./, a.n, i, j et k de son permis no 2666-V.Le droit de service à contrat accordé ne sera valide que tant et aussi longtemps que le contrôle actuel restera le même tant pour la firme Mercier Express Inc.que pour Urgel Charette Transport Ltée.The permit of the party mt«e en caute reads as follows: (o) General trucking - local service - (o) Mercier and ail points located within a distance of five (5) miles from the limits of said point; (b) General trucking - long distance -radius - (b) From Mercier to all points located within a radius of thirty (30) miles from the limits of said Town, and return; (e) General trucking - long distance -restricted route - irregular - (c) From Mercier to Valleyfield and Montreal, and return.Restriction: In pursuance of clauses a, b and c of his permit, the holder is not authorized to serve the Town of St.Rémi if said town is interpreted to be within a distance of five (5) miles from hia point of departure, Mercier.Service under contract: On behalf of Urgel Charette Transport Ltd.under the terms of clause a, b, e, d, e, f.g.h, i, j and * of their permit No.2666-V.The right of service under contract granted shall be valid as long as the present control remains the same for Mercier Express Inc.as well as for Urgel Charette Transport Ltée.Rôle Q-3525 Q-201767-D-6 FORTIER, THÉO 888.3e Avenue Val-d'Or (Que.) Q-202194 CERVAIS, GAÉTAN 174.chemin Baie-Carrière Val-d'Or (Que.) Demande de transfert: Fortier.Théo, demande à la Commission de transférer à: Gervais, Gaétan 174, chemin Baie-Carrière Val-d'Or (Que.) le permis no Q-201757-D-6 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération A-49, Val-d'Or.Application for transfer: Fortier, Théo, requests the Commission to transfer to: Gervais, Gaétan 174 Baie-Carrière Road Val-d'Or (Que.) permit No.Q-201757-D-6 to effect transport by taxicab in Conglomeration A-49.Val-d'Or.Rôle Q-3526 Q-201767-D-5 FORTIER, THÉO 888, 3e Avenue Val-d'Or (Que.) Q-200937-D-3 PELLERIN, YVON 798.3e Avenue Val-d'Or (Que.) Demande de transfert: Fortier.Théo, demande à la Commission de transférer à: Pellerin, Yvon 798, 3e Avenue Val-d'Or (Que.) le permis no Q-201767-D-5 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération A-49, Val-d'Or.Application for transfer: Fortier.Théo, requests the Commission to transfer to: Pellerin, Yvon 798-3rd Avenue Val-d'Or (Que.) permit No.Q-201767-D-5 to effect transport by taxicab in Conglomeration A-49.Val-d'Or.Rôle Q-3627 Q-201767-D-4 FORTIER, THÉO 888, 3e Avenue Val-d'Or (Que.) Q-200937-D-4 PELLERIN, YVON 798, 3e Avenue Val-d'Or (Que.) Demande de transfert: Fortier.Théo, demande à la Commission de transférer à: Pellerin, Yvon 798, 3e Avenue Val-d'Or (Que.) le permis no Q-201767-D-4 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération A-49, Val-d'Or.Application for transfer: Fortier, Théo, requests the Commission to transfer to: Pellerin, Yvon 798-3rd Avenue Val-d'Or (Que.) permit No.Q-201767-D-4 to effect transport by taxicab in Conglomeration A-49, Val-d Or.Rôle Q-3528 Q-201757-D-3 FORTIER, THÉO 888, 3e Avenue Val-d'Or (Que.) Q-202191 CLAVET, FERNAND 1, 9e Rue Val-d'Or (Que.) Demande de transfert: Fortier, Théo, demande à la Commission de transférer à: Clavet, 1 il n mu I 1, 9e Rue Val-d'Or (Que.) le permis no Q-201767-D-3 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération A-49, Val-d'Or.Application for transfer: Fortier, Théo, requests the Commission to transfer to : Clavet, I it ni m ! l-9th Street Val-d'Or (Que.) permit No.Q-201757-D-3 to effect transport by taxicab in Conglomeration A-49, Val-d Or. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3787 Rôle Q-3529 Q-201757-D-2 FORTIER, THÉO 888, 3e Avenue Val-d'Or (Que.) Q-200937-D-2 PELLERIN, YVON 798, 3e Avenue Val-d'Or (Que.) Rôle Q-3530 Q-201757-D-1 FORTIER, THÉO 888, 3e Avenue Val-d'Or (Que.) Q-200937-D-5 PELLERIN, YVON 798.3e Avenue Val-d'Or (Que.) Rôle Q-3531 Q-501202-D-001 HERVÉ ALLAIRE 118.avenue Pie X Victoriaville (Que.) et/and Q-5O5002-D-O01 RENÉ ALLAIRE 9, Fabiola Victoriaville (Que.) Rôle Q-3532 Q-200831-D-2 SUCCESSION EMILE PICARD Village Huron Loretteville (Que.) Q-202193-D-2 PICARD, RICHARD Village Huron Loretteville (Que.) Rôle Q-3533 Q-200831-D-1 SUCCESSION EMILE PICARD Village Huron Loretteville (Que.) Q-202193-D-1 PICARD, RICHARD Village Huron Loretteville (Que.) Rôle Q-3534 Q-502867-D-001 GEORGES THIBAULT LTslet-sur-Mer (Que.) et/and Q-605007-D-O01 CILBERT THIBAULT L'Islet-sur-Mer (Que.) Rôle Q-3550 Q-200341 FERLAND, GASTON 444, Plante Ville Vanier (Que.) Q-201776-D-2 DROUIN, AURÉLIEN 296, 52e Rue oueet Charlesbourg (Que.) Demande de transfert: Fortier, Théo, demande à la Commission de transférer à: Pellerin, Yvon 798, 3e Avenue Val-d'Or (Que.) le permis no Q-201757-D-2 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération A-49, Val-d'Or.Demande de transport: Fortier, Théo, demande à la Commission de transférer à: Pellerin, Yvon 798, 3e Avenue Val-d'Or (Que.) le permis no Q-201757-D-1 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération A-49, de Val-d'Or.Demande de transfert: Hervé Allaire demande à la Commission de transférer par donation à: René Allaire 9.Fabiola Victoriaville (Que.) le permis ou l'attestation Q-501202-D-001 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac, dans la région no 4, catégorie Artisan.Demande de transfert: Succession Emile Picard demande à la Commission de transférer à: Picard, Richard Village Huron Loretteville (Que.) le permis no Q-20083 l-D-2 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération (A-36, Québec.Application for transfer: Fortier, Théo, requests the Commission to transfer to: Pellerin, Yvon 798, 3rd Avenue Val-d'Or (Que.) permit No.Q-201757-D-2 to effect transport by taxicab in Conglomeration A-49, Val-d'Or.Application for transfer: Fortier.Théo, requests the Commission to transfer to: Pellerin.Yvon 798, 3rd Avenue Val-d'Or (Que.) permit No.Q-201757-D-1 to effect transport by taxicab in Conglomeration A-49, Val-d'Or.Application for transfer: Hervé Allaire requests.the Commission to transfer by donation to: René Allaire 9 Fabiola Victoriaville (Que.) permit or certificate Q-501202-D-001, which he holds, to effect bulk trucking in Region No.4, Artisan class.Application for transfer: Succession Emile Picard requests the Commission to transfer to: Picard, Richard Village Huron Loretteville (Que.) permit No.Q-200831-D-2 to effect transport by taxicab in Conglomeration A-36, Québec.Demande de transfert: Succession Emile Picard demande à la Commission de transférer à: Picard, Richard Village Huron Loretteville (Que.) l'attestation no Q-200831-D-1 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans la région suivante: la municipalité de Village Huron.Demande de transfert: Georges Thibault demande à la Commission de transférer par donation à : Gilbert Thibault L'Islet-sur-Mer (Que.) le permis ou l'attestation Q-502867-D-001 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac dans la région no 3, catégorie Artisan.Demande de transfert: Ferland, Gaston, demande à la Commission de transférer à: Drouin, Aurélien 295, 52e Rue ouest Charlesbourg (Que.) le permis no Q-200341 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération A-36, Québec.Application for transfer: Succession Emile Picard requests the Commission to transfer to: Picard, Richard Village Huron Loretteville (Que.) the attestation No.Q-200831 to effect transport by taxicab in the following region: the Municipality of Village Huron.Application for transfer; Georges Thibault requests the Commission to transfer by donation to: Gilbert Thibault LTslet-sur-Mer (Que.) the permit or certificate Q-502867-D-001, which he holds, to effect bulk trucking in Region No.3, Artisan class.Application for transfer: Ferland, Gaston, requests the Commission to transfer to: Drouin, Aurélien 295, 52th Street West Charlesbourg (Que.) permit No.Q-200341 to effect transport by taxicab in Conglomeration A-36, Québec. 3788 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1976, Vol.107, No.19 Rôle Q-3552 Q-5004SO-D-001 JEAN-PAUL ROUSSEAU 1376, boul.Laure Sept-Iles (Que.) et/and Q-5O4961-D-001 JIMMMY CONNORS 14,rue Leventoux Sept-Iles (Que.) Rôle Q-3565 Q-504033-D-001 GERMAIN LAROUCHE (Antonio Larouche.légataire universel / sole legatee) 763, Walberg Dolbeau (Que.) et/and Q-502720-D-003 ANTONIO LAROUCHE 1681, Walberg Dolbeau (Que.) Rôle Q-3571 Q-501730-D-001 ROLAND CARON 511, Principale Ville Dégelis (Que.) et/and Q-504995-D-001 RINO LÉVESQUE 265, Principale Ville Dégelis (Que.) Rôle Q-3572 Q-501382-D-002 RAYMOND DIONNE St-Mathieu (Rimouski) (Que.) et/and Q-504833-D-001 RENAUD DIONNE St-Mathieu (Rimouski) (Que.) Q-504833-D-OO1 Rôle M-8394 3046-A (D.5.) LAURENTIAN AUTOBUS ENR'G., LAURENTIAN SCHOOL & CAMP BUS RF.G'D., (M.Morris Torontour, opérant sous le nom de / operating under the name of 555 Laurentian Blvd., App.103, Ville St-Laurent.(Que.) Demande de transfert: Jean-Paul Rousseau demande à la Commission de transférer à: Jimmy Connors 14,rue Leventoux Sept-Iles (Que.) le permis ou l'attestation Q-500450-D-001 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac dans la région no 9, catégorie Entrepreneur.Application for transfer: \u201e .Jean-Paul Rousseau requests the Commission to transfer to: Jimmy Connors 14 Leventoux Street perm^or^e'rtificate Q-500450^D-001, which he holds to effect bulk trucking in Region No.9, Contractor class.Demande de transfert: Germain Larouche (Antonio Larouche, légataire universel), demande à la Commission de transférer par succession à: Antonio Larouche 1681.Walberg Dolbeau (Que.) le permis ou l'attestation Q-504033-D-001 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac, dans la région no 2, catégorie Artisan.Application for transfer: Germain Larouche, (Antonio Larouche, sole legatee), requests the Commission to transfer by succession to: Antonio Larouche 1681 Walberg Dolbeau (Que.) permit or certificate Q-504033-D-001, which he holds, to effect bulk trucking in Region 2, Artisan class.Demande de transfert: Roland Caron demande à la Commission de transférer à: Rino Lévesque 265, Principale Ville Dégelis (Que.) le permis ou l'attestation Q-501730-D-001 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac, dans la région no 3, catégorie Artisan.Application for transfer: Roland Caron requests the Commission to transfer to: Rino Lévesque 265 Principale Ville Dégelis (Que.) permit or certi ficate Q-501730-D-O01, which ne holds.to effect bulk trucking in Region No, 3.Artisan class.Demande de transfert: Raymond Dionne demande à la Commission de transférer à: Renaud Dionne St-Mathieu (Rimouski) (Que.) le permis ou l'attestation Q-501382-D-O02 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac dans la région no 1, catégorie Artisan.Application for transfer: Raymond Dionne requests the Commission to transfer to: Renaud Dionne St-Mathieu (Rimouski) (Que.) permit or certificate Q-501382-D-002.which he holds, to effect bulk trucking in Region No.1, Artisan class.La requérante s'est adressée à la Commission des transports du Québec afin d'obtenir l'autorisation d'effectuer les services suivants: Classe de permis: (Service d'autobus) La requérante demande à la Commission des transports l'autorisation d'effectuer avec autobus (67 passagers) le transport d'enfants de quatre (4) à douze (12) ans fréquentant le Y.M.- Y.W.H.A.& N.H.S.of Montréal 6itué à 6500 ave.Westbury, Montréal, entre les heures de 9.00 a.m.et 4.00 p.m.Service no 1: Ce service inclut les excursions suivantes: a) 18 excursions du Y.M.- Y.W.H.A.& N.H.S.au t Y \u2022 Country Camp situé à St-Jovite, et retour - 6) 6 excursions dans un rayon de 20 milles de l'Ile de Montréal, et retour - e) 4 excursions dans un rayon de 40 milles de l'Ile do Montréal, et retour - o) 4 excursions à Ottawa, et retour - e) 18 excursions dans un rayon de 60 milles de l'Ile de Montréal, et retour - The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following services: Class of permit: (Bus service) The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to effect, by bus, (67-passenger) the transport of children aged four (4) to twelve (12) years, attending activities at the Y.M.-Y.W.H.A.and N.H.S.of Montreal located at 5500 Westbury Avenue, Montreal, between 9.00 a.m.and 4.00 p.m.Service No.1 : This service includes the following excursions: (a) 18 excursions from the Y.M.- Y.W.H.A.and N.H.S.to the \"Y\" Country Camp located in St-Jovite, and return- (6) 6 excursions within a radius of 20 miles from the Island of Montreal, and return- (c) 4 excursions within a radius of 40 miles from the Island of Montreal, and return - W 4 excursions to Ottawa, and return - M 18 excursions within a radius of 60 miles from the Island of Montreal, and return - GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3789 /) La navette journalière transportant les enfants sera faite d'un endroit à l'autre des camps suivants: 1.Y.M.- Y.W.H.A.& N.H.S.of Montreal, 5600, ave.Westbury.Montréal (Que.) 2.Van Horne School, 4810, Van Horne, Montréal (Que.) 3.Wentworth School.8205 Mackle, Montréal (Que.) 4.Davis « Y \u2022 5700, Kellert, Montréal (Que.) 6.Neighborhood House, 6645, ave.Darlington, Montréal (Que.) Service no 2: La requérante aussi fournira le service de n'importe où sur l'Ile de Montréal aux susdites écoles (voir /) entre 7.30 a.m.et 10.00 a.m.et 4.00 p.m.à 5.00 p.m.avec autobus (minibus 25 passagers).Ses services seront opérés durant les mois de juillet et août 1976.(/) Children will be transported daily from any one to any other of the following camps: 1.Y.M.- Y.M.H.A.and N.H.S.of Montreal, 5500 Westbury Avenue, Montreal.P.Q.2.Van Home School, 4810 Van Horne, Montreal, P.Q.3.Wentworth School, 8205 Mackle, Montreal, P.Q.4.Davis \"Y\", 5700 Kellert, Montreal, P.Q.5.Neighborhood House, 6645 Darlington Avenue, Montreal, P.Q.Service No.2: The applicant also shall provide a service from any point on the Island of Montreal, to the aforesaid schools (see \"/\") between 7:30 a.m.and 10:00 a.m.and 4:00 p.m.to 5:00 p.m.with bus (25 passenger minibus).These services shall be operated during the months of July and August, 1976, 60769-o II \u2014 Avis d'introduction de requêtes - Erratum Edition numéro 16 du 19 avril 1975, à la page 3279, au paragraphe concernant la demande de Marcel Héroux et Léo Roy, avant-dernière ligne, nous aurions du lire: « dans la région no 4 » au lieu de: « dans la région no 2 ».00758-O V \u2014 Avis de décisions rendues: La Commission donne avis de la nature des décisions suivantes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlement 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément à Panicle 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication V \u2014 Notice of decisions rendered: The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it.in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation 2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.AUDIENCES PUBLIQUES \u2014 TRANSPORTS PUBLICS \u2014 ECOLIERS PUBLIC HEARINGS \u2014 PUBLIC TRANSPORT \u2014 STUDENTS No\tDale\tRequérants Applicants\tCause Case\tDécisions PE-247\t30-04-75\tM-100-006 COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE SALABERRY Mise en cause M-100-042-D-1 VENISE COACH LINES INC.\tM-2824\tPrix du conirai approuvé./ Contract price approved.Déiails de la demande: Demande parue dans le journal «La Presse)) les 20.21 aoûl 1974.QPE-511 29-04-75 Particulars of application: Application published in the newspaper \"La Presse\" August 20, 21, 1974.Q-100-019-D-2 GREATER QUEBEC SCHOOL BOARD Détails de la demande: Demande de reconnaissance de commission scolaire Q-1651 Accordée / Granted Particulars of application: Request for recognition of school board. .'47! KI QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 V \u2014 Avis de décisions rendues: La Commission donne avis de la nature des décisions suivantes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlemenl 2.Dans le cas d'une déci-â l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.V \u2014 Notice of decisions rendered: The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it, in conformity with the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act.the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.AUDIENCES PUBLIQUES I PUBLIC HEARINGS \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCauses\t No\tDale\t\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\tCase\t MCR-1902\t24-04-75\tI949-V-D-II\t5164\t20-07-74\tM-2537\tRejetée / Rejected MCS-1171\t\tLEON FRIEDMAN Requérant-vendeur Applicant-vendor DELMAR TRANSPORT CORPORATION Requéranie-acquéreur Applicant-purchaser Transfert de clause Transfer of clause\t\t\t\t MCR-1807\t24-04-75\t299-V-D-3 DIAL TRANSPORT LIMITED Modification de permis Modification of permit\t6852\t21-09-74\tM-3039\tDésistement Withdrawal MCV-4472\t07-04-75\tM-50I990-D-0O4\t5286\t27-07-74\tM-2570\tRejetée / Rejected \t\tTRANSPORT LESAGE LTEE\t\t\t\t \t\tTransfert de région\t\t\t\t \t\tTransfer of region\t\t\t\t MCV-4473\t07-04-75\tM-50I990-D-003\t5285\t27-07-74\tM-2569\tRejetée / Rejected \t\tTRANSPORT LESAGE LTEE\t\t\t\t \t\tTransfert de région\t\t\t\t \t\tTransfer of region\t\t\t\t MCV-4474\t08-04-75\tM-5OI990-D-002\t5285\t27-04-74\tM-2568\tRejetée / Rejected \t\tTRANSPORT LESAGE LTEE\t\t\t\t \t\tTransfert de region\t\t\t\t \t\tTransfer of region\t\t\t\t MCV-447J\t08-04-75\tM-50I990-D-00I\t5285\t27-07-74\tM-2567\tRejetée 1 Rejected \t\tTRANSPORT LESAGE LTEE\t\t\t\t \t\tTransfert de région\t\t\t\t MPT-8756-\t\tTransfer of region\t\t\t\t \t25-04-75\tM-20002-D-I-TF\t9003\t30-11-74\tM-3936\tAccordée / Grunted TF\t\tLA LIGUE DE TAXIS DE LONGUEUIL INC Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCR-I8I3\t28-04-75\tM-22026-V\t3228\t26-05-73\tM-4396-R\tRejeiée / Rejected \t\tA.L.DISTRIBUTIONS ENRG.\t\t\t\t \t\tDroit additionnel\t\t\t\t \t\tAdditional ricin\t\t\t\t MCR-1814\t28-04-75\tM-23648-V-D-I\t5468\t03-08-74\tM-2693\tAccordée / Granted \t\tTRANSPORT B.R.M.INC.\t\t\t\t \t\tNouvelle demande\t\t\t\t \t\tNew application\t\t\t\t MCR-I8IÎ\t29-04-75\t36S-V-D-I FORGET TRANSPORT INC Vérificaiion de permis Verification of permit\t29Pf!\t20-04-74\tM-1660\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3791 No Date Requéranls Applicants GOO.page dale Cause Case Décisions 77-V P.E.LAFRAMBOISE TRANSPORT ENR.Intimé I Respondent La Commission avise la détentrice, P.E.Laframboise Transport Enrg., (Dame Marie-Anne Brisson opérant sous le nom de:) de cesser de donner le service qu'elle exploite actuellement, des points intermédiaires situés entre Si-Jérôme cl Montréal à Montréal et retour, tani que la Commission n'aura pas sialué sur la requête en modification.The Commission requires the holder.P.E.Laframboise Transport Enrg., (Mrs.Marie-Anne Brisson operating under the name of) lo suspend her present service from intermediate points between St.Jerome and Montreal to Montreal and reium.so long as the Commission has not ruled upon Ihe application for modification.MCS-1175 MCS-1177 OCR-1018 OCS-556 QSM-76 QSM-77 29-04-75 29-04-75 25-04-75 25-04-75 28-04-75 28-04-75 20667-V-D-3 JEFFERY'S CARTAGE LTD.Droit additionnel Additional right 112I7-V-D-4 ATOMIC TRUCK CARTAGE LTD.Modification de permis Modification of permit 21093-V-D-3 L BILODEAU & FILS LTEE Modification de permis Modification of permit 18208-V-D-l ALCIDE DOYON I97-N-D-I L'ASSOCIATION DES BATELIERS DE PERCE ENRG.& LES BATELIERS C PERCE INC.I97-N-D-I L'ASSOCIATION DES BATELIERS PERCE ENRG.& LES BATELIEI PERCE INC.QPT-3120 25-04-75 O-2CO445-D-002 RENE LANDRY Requérant-cédant Applicant-transferror Q-202078-D-0O2 ROGER LEBEL Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit QPT-3121 25-04-75 O-200445-D-1 RENE LANDRY Requérant-cédanl Applicant-transferror O-202078-D-I ROGER LEBEL Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit MCV-4635 29-04-75 M-500224-P-001 ELPHEGE BROCHU La Commission déclare amendée la décision numéro MCV-117 de la cause MV-0017.aux fins que: dans la décision susmenlionnée la ((Catégorie Entrepreneur» soit remplacée par la «catégorie Artisan».DE 4431\t15-06-74\tM-2058 5300\t27-07-74\tM-2627 5549\t03-08-74\t 7005\t28-09-74\t0-1933 7004\t28-09-74\t0-I93I 5475\t22-09-73\tO-0I58 5475 E\t22-09-73\tO-0158A 7622\t12-10-74\tQ-2026 7622\t12-10-74\tQ-2027 9196\t07-12-74\tM-4067 Rejetée / Rejected Rejetée / Rejected Accordée en partie Partly granted Accordée telle qu'amendée Granted as amended La Commission accorde les requêtes 1 et 2 telles qu'amendées./ The Commission grants requests I and 2 as amended.La Commission accorde la requête no 3./ The Commission grants request No.3.Accordée / Granted Accordée / Granted garding case MV-0017.amended for ihe following purposes: lo substitute, in Ihe aforesaid decision.\"Artisan class\" for \"Con-iracior class\". 3792 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 No\tDale\tRequérante Applicants\tG page\to.o.dale\tCause Case\tDécisions MCV-4636\t29-04-75\tM-50O315-P-0O1 LUCIEN DIONNE\t9196\t07-12-74\tM-4066\t La Commission déclare amendée la décision numéro MCV-112 de la cause MV-0012, aux fins que: dans la décision susmemionnée la «calégoric Entrepreneur» soil remplacée par la «catégorie Artisan».MCV-4638 29-04-75 M-502808-P-00I |ROGER DESROCHES La Commission déclare amendée la décision numéro MCV-1872 de la cause MV-1772.aux fins que: dans la décision susmentionnée le nom du requérant se lise comme suit: Desroches.MCV-4640 29-04-75 M-503162-P-00I JEAN-MARC PILON La Commission déclare amendée la décision'numéro MCV-959 de la cause MV-0859.aux fins que: dans la décision susmentionnée l'adresse du requérant se lise comme suit: 121.Curé-Labelle.Labelle.comté de Labelle (Que.).MCV-4642 29-04-75 M-504038-P-001 DI MENNA GUY La Commission déclare amendée la décision numéro MCV-2943 de la cause MV-2843.aux fins que: dans la décision susmentionnée l'adresse du requérant se lise comme suit: 2495.Fleury.Montréal (Que.).MCV-4643 29-04-75 M-502770-P-001 PAUL TAILLEFER La Commission déclare amendée la décision numéro MCV-2033 de la cause MV-1933.aux fins que: dans la décision susmentionnée l'adresse du requérant se lise comme suit: 13.Des Ormes.Domaine Laurenlien.St-Jérôme.comté de Terrebonne (Que.).MCV-4644 29-04-75 M-5OO271-P-0OI | ARMAND BEDARD La Commission déclare amendée la décision numéro MCV-108 de la cause MV-0008, aux fins que: dans la décision susmentionnée la «catégorie Entrepreneur» soil remplacée par la «catégorie Artisan».MCV-4645 29-04-75 M-500723-P-00I i ROGER DUMAS La Commission déclare amendée la décision numéro MCV-994 de la cause MV-0894, aux fins que: dans la décision susmentionnée le numéro de la décision se lise comme suit: M-500723.MCV-4646 29-04-75 M-5O0243-P-O0I HARRY BRUNEAU La Commission déclare amendée la décision numéro MCV-1563 de la cause MV-1463.aux fins que: dans la décision susmemionnée le numéro de la décision se lise comme suit : M-500243.MCV-4647 29-04-75 M-504647-P-001 SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE The Commission declares decision number MCV-112, regarding case MV-2843, amended for the following purposes: lo substitute, in the aforesaid decision.\"Artisan class\" for \"Contractor class\".9194 07-12-74 M-4045 The Commission declares decision number MCV-1872, regarding case MV-1772, amended for Ihe following purposes: lhal Ihe applicant's name, in Ihe aforesaid decision, read as follows: Desroches.j 9195 J 07-12-74 J M-4063 | The Commission declares decision number MCV-959, regarding case MV-0859, amended for the following purpose: thai the applicant's address, in the aforesaid decision, read as follows: 121 Curé-Labelle, Labelle, County of Labelle.P.O.9195 07-12-74 M-4061 The Commission declares decision number MCV-2943.regarding case MV-2843, amended for the following purpose: that the applicant's address in the aforesaid decision, read as follows: 2495 Fleury, Montreal.P.Q.9195 07-12-74 M-4060 The Commission declares decision number MCV-2033, regarding case MV-1933.amended for Ihe following purpose: lhal Ihe applicant's address, in Ihe aforesaid decision, read as follows: 13 Des Ormes, Domaine Laurenlien.St-Jérôme.County of Terrebonne.P.Q.9195 07-12-74 M-4059 The Commission declares decision number MCV-108.regarding case MV-0008.amended for the following purpose: to substitute, in the aforesaid decision, \"Artisan class\" for \"Con-tracior class\".9195 07-12-74 M-4058 The Commission declares decision number-MCV-994 regarding case MV-0894, amended for Ihe following purpose: lhal Ihe decision number in Ihe aforesaid decision read as follows: M-500723.9195 07-12-74 M-4057 The Commission declares decision number MCV-1563, regarding case MV-1463, amended for the following purpose: lhal Ihe decision number, in the aforesaid decision, read as follows: M-500243.9195 07-12-74 M-4056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3793 No\tDale\tRequérants Applicants\tG page\tO.Q.dale\tCause Case\tDécisions La Commis cause MV-270 dans la décisi comme suit: 1 Si-Hyacinthe ( MCV-4648\tion déclar 7, aux fins on susmer 16, St-Thi Que.).29-04-75\t: amendée la décision MCV-2807 de la Tt que: MV-lionnée l'adresse du requérant se lise lhal mas.St-Denis-sur-Richelieu, comlé de read of St M-501103-P-001 DA SILVA ARMANDO\te décisi 2707 am he appl as follov -Hyacinl 9195\ton declare ended for I) cant's addr /s: 116 St-1 he, P.O.07-12-74\t> decision N e following ess appearin 'nomas, St-C M-4055\t1CV-2807 regarding case purposes: 5 in the aforesaid decision enis-sur-Richelieu, County La Commission déclare amendée la décision MCV-2403 de la cause MV-0017, aux fins que: dans la décision susmentionnée le nom du requérant se lise comme suit: Da Silva.MCV-4649 The Commission declares decision MCV-2403 regarding case MV-0017, amended, for the following purposes: thai the applicant's name, which appears in the aforesaid decision, read as follows: Da Silva.29-04-75 M-504244-P-001 AIME DUFRESNE La Commission déclare amendée la décision numéro MCV-3333 de la cause MV-3233, aux fins que: dans la décision susmentionnée l'adresse du requérant se lise comme suit: 3925 boul.St-Martin, Chomedey.ville de Laval (Que.).9195 07-12-74 M-4054 MCV-4650 29-04-75 M-502680-P-001 JUDES COULOMBE La Commission déclare amendée la décision susmentionnée la «catégorie Entrepreneur»: soil remplacée par la «catégorie Ar- The Commission declares decision number MCV-3333 regarding case MV-3233 amended for the following purposes: that Ihe applicant's address appearing in the aforesaid decision read as follows: 3925 St-Manin, Chomedey Blvd., City of Laval.P.Q.9194 J 07-12-74J M-4053 The Commission declares ihe aforementioned decision amended as follows: substitute \"Artisan class\" for \"Contractor class\".MCV-465! 29-04-75 M-500193-P-00i EDGAR SAVOIE La Commission déclare amendée la décision numéro MCV-101 de la cause MV-0001, aux fins que: dans la décision susmentionnée la «catégorie Entrepreneur» soit remplacée par la « catégorie Artisan ».9194 07-12-74 M-4052 MCV-4652 The Commission declares decision number MCV-101 regarding case MV-0001 amended, for ihe following purposes: substituting, in Ihe aforesaid decision, \"Artisan class\" for \"Contractor class\".29-04-75 M-502678-P-001 PIERRE PRATTE La Commission déclare amendée la décision numéro MCV-114 de la cause MV-0014, aux fins que: dans la décision susmentionnée la «catégorie Entrepreneur» soit remplacée par la «catégorie Artisan».9194 07-12-74 M-4051 The Commission declares decision number MCV-114, regarding case MV-0014, for the following purposes: substituting, in the aforementioned decision.\"Artisan class\" for \"Contractor class\".MS-1454 28-04-75 2186-A-S-3 HUGUETTE LEBOEUF La Commission décrète le remboursement du cautionnement déposé par Métropolitain Provincial (1967) Inc.dans le dossier de la requête no RS-0552.QCR-1015 25-04-75 9197 07-12-74 M-4073 The Commission orders the reimbursement of the deposit filed by Métropolitain Provincial (1967) Inc.in the file pertaining to application No.RS-0552.2820 29-03-75 Q-3234 3761-V-P-l DAME DOROTHEE CELESTE FORTIN .La Commission révoque la décision autorisant l'émission du The Commission revokes the decision authorizing Ihe issue of permis no 3761-V et annule ledit permis à toutes fins que de droil.permit No.3761-V and cancels said permit, for all legal purposes.QCR-1016 25-04-75 23981-V-P-l PAUL OUELLET Voiturier-remorqueur Haulaway operator 15944-V LOGISTEC CORPORATION Voiturier-roulier / Carrier 2820 29-03-75 Q-3273 3794 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 No\tDale\tRequérants Applicants\tG page\tO.Q.dale\tCause Caje\tDécisions \t\t\t\t\t\t La Commission: 1.révoque la décision autorisant l'émission du permis du tireur, Paul Ouellel (23981-V), connexe à la décision autorisant la délivrance du permis du tiré.Logislec Corporation.2.révoque également la décision autorisant l'émission du permis du tiré, Logislec Corporation (15944-V).connexe à la décision autorisant la délivrance du permis du tireur, Paul Ouellel; 3.annule lesdits permis à louies fins que de droit.QCR-I0I7 25-04-75 20984-V-PI LES ENTREPRISES MONT STERLING INC.La Commission, à la demande du détenleur.révoque la ou les décisions autorisant l'émission du permis no 20894-V et annule ledit permis' à toutes fins que de droit.OCR-1023 28-04-75 8797-V-P-l-TF & 8797-V-D-2-TF I DOLBEC TRANSPORT INC.La Commission: I.fixe les taux selon le dossier: 2 décrète la remise du cautionnement de $50 effectué par Dolbec Transport Inc.avec sa requête (reçu 31484).The Commission: 1.revokes the decisions authorizing Ihe issue of Ihe permit held by the haulaway operator, Paul Ouellel (23981-V), which decision is related to that authorizing the issue of Ihe permit held by the carrier.Logislec Corporation; 2.also revokes Ihe decision authorizing the issue of the permit held by the carrier.Logislec Corporation (15944-V), which decision is related lo lhal authorizing the issue of ihe permit held by the haulaway operator.Paul Ouellel; 3.cancels said permits for all legal purposes.2820 29-03-75 0-3274 The Commission revokes, at the holder's request, the deci-sion(s) authorizing the issue of permit No.20894-V.and cancels said permit, for all legal purposes.2823 29-03-75 Q-3199 0-2885 The Commission: 1.fixes Ihe rales according to the file; 2.orders the reimbursemenl of the $50 deposit effected by Dolbec Transport Inc.together with its application (receipl 31484).0CS-557 28-04-75 23135-V-P-l GILLES PELLETIER La Commission: 1.révoque la décision autorisant l'émission du permis 23135-V.en faveur de Gilles Pelletier, tireur, connexe avec le permis du tiré.Brazeau Transport Inc.; 2.annule ledit permis 23135-V à toutes fins que de droit.0CV-2223 2823 29-03-75 Q-3233 The Commission: 1.revokes the decision authorizing the issue of permit 23135-V in behalf of Gilles Pelletier, haulaway operator, said permit being related to Ihe permit held by the carrier.Brazeau Transport Inc.; 2.cancels said permit 23135-V.for all legal purposes.28-04-75 O-504173-P-1 I DE L'ORME CONSTRUCTION LTEE La Commission confisque le cautionnement de $50 fait avec la requête O-504173-D-00I.OCV-2224 28-04-75 29-03-75 0-3186 The Commission confiscates the $50 deposit made with application O-504I73-D-001.O-50I490-P-00I BORROMEE PLOURDE La Commission: 1.corrige le nom du requérant dans la décision QCV-1982 pour qu'il se lise: Borromée Plourde.2.corrige le numéro du dossier dans ladite décision OC V-1982 pour qu'il se lise: Q-50I490-D-002.OPT-3124 25-04-75 Q-20I003-P-I | WELLIE GERVAIS La Commission prend et donne acte: 1.révoque, à toutes fins que de droit, la décision QPT-729; 2, révoque le permis O-200744-D-00I.QPT-3125 25-04-75 Q-200905-P-1 I GERARD FORTIN La Commission révoque le permis de propriétaire de taxi détenu par M.Gérard Fortin lequel fui autorisé par décision QPT-0506 du 12 juillet 1974.2823 29-03-75 0-3262 The Commission: 1.corrects the applicant's name appearing in decision QCV-1982 lo read as follows: Borromée Plourde.2.corrects the file number appearing in said decision QCV-1982 lo read as follows: O-501490-D-002.29-03-75 Q-3185 OPT-3126 25-04-75 O-201779-P-I ANTOINE BOLDUC The Commission records and gives notice thai it; 1.revokes decision QPT-729, for all legal purposes; 2.revokes permit No.Q-200744-D-001.29-03-75 Q-3189 The Commission revokes the taxicab owner's permit held by Mr.Gérard Fortin, the issue of which was authorized by decision QPT-0506.rendered on July 12.1974.29-03-75 Q-3188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n\" 19 3795 No\tDale\tRequérants Applicants\tG page\t.O.O.date\tCause Case\tDécisions \t\t\t\t\t\t La Commission révoque la décision QPT-0308 du 9 juillet 1974 et par conséquent annule le permis de propriétaire de taxi détenu par M.Antoine Bolduc (Q-201779-D-1).MPV-489 24-04-75 3024-A-P-l | LES AUTOBUS BROMONT INC.La Commission révoque el annule, à toutes fins que de droits, le permis émis en faveur des Autobus Bromont Inc.pour un service urbain dans la ville de Bromont.The Commission revokes decision QPT-0308 rendered on July 9.1974 and consequently cancels Ihe laxicab owner's permit held by Mr.Antoine Bolduc (Q-201779-D-1).9196 07-12-74 M-4069 The Commission revokes and cancels, for all legal purposes.Ihe permil issued in behalf of Autobus Bromont Inc.for an urban service in the Town of Bromont.SEANCES EN CHAMBRE I SITTINGS IN CHAMBERS MPV-490-\t24-04-75\t725-A-D-l-TF\t1016\t25-01-75\tM-5220\tAccordée / Granted TF\t\tC.MONETTE & FILS LTEE Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MPV-491\t24-04-75\t2095-A-D-2 JEAN-PAUL AMESSE Requérant-vendeur Applicant-vendor TRANSPORT AMESSE INC.Requérant-acquéreur Applicant-purchaser Transfert de permis Transfer of permil\t1867\t01-03-75\tM-6358\tAccordée / Granted MPT-8755\t23-04-75\tM-206201 MARCEL BLANCHETTE Demande de permis Application for permit\t1764\t22-02-75\tM-6289\tAccordée / Granted MCR-1753-\t14-04-75\t18550-V-D-2-TF\t1856\t01-03-75\tM-6306\tAccordée 1 Granted TF\t\tPUROLATOR COURIER LTD.Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCR-1754-\t14-04-75\t519-V-D-2-TF\t1865\t01-03-75\tM-6331\tAccordée / Granted TF\t\tLANGLOIS TRANS ENR.Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCR-1797\t23-04-75\t953I-V-D-2 DAME GERTIE HILLIMAN-VIEN Requérante-venderesse Applicant-vendor WESTWAY TRANSPORT (QUEBEC)LTD.Requérante-acquéreur Applicant-purchaser Transfert de permis\t1579\t15-02-75\tM-6244\tAccordée / Granted MCR-1798\t24-04-75\tTransfer of permil 432-V-D-l NOEL ARCHAMBAULT Requérant-vendeur A pplicant- vendor 4608-V PAPINEAU TRANSPORT INC.Requérant-acquéreur Applicant-purchaser Transfer! de permis\t1181\t01-02-75\tM-6065\tAccordée / Granted MCR-1799\t24-04-75\tTransfer of permil 22212-V-D-l GERMAIN PROVENCHER Modification de clause Clause modification\t975\t25-01-75\tM-4890\tAccordée / Granted 3796 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérante Applicants\t\t\tCause\t No\tDale\t\tpage\tdate\tCase\tDécisions MCR-1801-\t24-04-75\tM-30004-D-4-TF\t1455\t16-02-74\tM-1053\tRejetée / Rejected TF\t\tCANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASSN.Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCR-1803-\t24-04-75\t16635-V-D-l-TF\t1367\t08-02-75\tM-5411\tAccordée / Granted TF\t\tP.A.BONNEAU INC.Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCR-1804-\t24-04-75\t30007-D-18-TF\t1367\t08-02-75\tM-5412\tAccordée / Granted TF\t\tSOUTHERN MOTOR CARRIERS RATE CONFERENCE Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCR-1805-\t24-04-75\t30007-D-17-TF\t1365\t08-02-75\tM-5407\tAccordée / Granted TF\t\tSOUTHERN MOTOR CARRIERS RATE CONFERENCE Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCR-1806\t24-04-75\t6595-V-D-l\t57\t04-01-75\tM-4630\tAccordée / Granted MCS-1172\t\tBERGERON TRANSPORT LIMITED Requérante-venderesse Applicant-vendor TRANSPORT BERGERON! 1974) LTEE Requérante-acquéreur Applicant-purchaser Transfert de permis Transfer of permil\t\t\t\t MCR-1808\t24-04-75\t23680-V-D-l\t1752\t22-02-75\tM-6204\tAccordée / Granted \t\tL'AGENCE DE SECURITE\t\t\t\t \t\tPHILLIPS INC.\t\t\t\t \t\tNouvelle demande\t\t\t\t \t\tNew application\t\t\t\t MCR-1809\t24-04-75\tI0374-V-D-3\t9011\t30-11-74\tM-3995\tAccordée / Grained MCS-1173\t\tA-l MOVING & TRANSPORT LTD.Transfert d'actions Transfer of shares\t\t\t\t MCS-II69\t24-04-75\t22315-V-D-l\t8047\t26-10-74\tM-3489\tAccordée / Granted \t\tOUTREMONT EXPRESS INC.\t\t\t\t \t\tVoilurier-remorqueur\t\t\t\t \t\tHaulaway operator\t\t\t\t \t\tNouvelle demande\t\t\t\t \t\tNew application\t\t\t\t \t\t6793-V\t\t\t\t \t\tBRA7.EAU TRANSPORT INC.\t\t\t\t \t\tVoiturier-roulier / Carrier\t\t\t\t \t\tDroit additionnel\t\t\t\t \t\tAdditional right\t\t\t\t MCS-II70-TF\t24-04-75\t7I3-V-D-4-TF LAKESHORE MOVERS AND WAREHOUSING (CAN.) LTD.Modification de tarif Tariff modification\t1012\t25-01-75\tM-5195\tAccordée / Granted MCV-4568\t24-04-75\tM-50359I-D-00I EMILE ST-DENIS Requérant-vendeur Applicant- vendor M-5034I5-D-00I MAURICE DAOUST Requéranl-acqucreur Applicant-purchaser Transfert d'attestation Transfer of certifiant\t1755\t22-02-75\tM-6230\tAccordée 1 Grunted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n\" 19 3797 \t\t\tGOO.\t\t\t No\t\tRequérants\t\t\tCause\t \tDale\t\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\tCase\t MPV-492-\t25-05-75\t2525-A-D-l-TF\t1857\t01-03-75\tM-6308\tAccordée / Granted TF\t\tBRUNO E.GRISE TRANSPORT INC.Modification de permis Modification of permit\t\t\t\t MPV-493-\t28-04-75\t1491-A-D-l-TF\t1863\t01-03-75\tM-6329\tAccordée / Granted TF\t\tLA COMPAGNIE DE TRANSPORT MASKOUTAINE INC.Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MPT-8757\t25-04-75\tM-20015-D-I LA LIGUE DE TAXIS DE ST-JEROME INC.Nouvelle demande New application\t1757\t22-02-75\tM-6243\tAccordée / Granted MPT-8758\t25-04-75\tM-200666-D-I-D-2 ANDRE RANGER Prolongement de service Extension of service\t9014\t30-11-74\tM-4083\tAccordée / Granted MPT-8759\t21-04-75\tM-2O209I JOSEPH FOURNIER Requérant-cédant Applicant-transferror M-206223 JEAN GIBEAULT Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit\t2082\t08-03-75\tM-6543\tAccordée / Granted MPT-8760\t21-04-75\tM-203607 WILLY DE RIDDER Requérant-cédant Applicant-transferror M-206232 SALOMON A BIT BOL Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permil\t2082\t08-03-75\tM-6542\tAccordée / Granted MPT-8761\t21-04-75\tM 204448-D-2 SHAMSHER SINGH Requérant-cédant Applicant- transferror M-206214-D-1 MME RAYMONDE BARRIERE Requérante-cessionnaire Applicam-iransferee Transfert de permis Transfer of permil\t1765\t22-02-75\tM-6343\tAccordée / Granted MPT-8762\t21-04-75\tM-20445I-D-2 10BAL SINGH Requérant-cédant Applicant-transferror M-206214-D-2 MME RAYMONDE BARRIERE Requérante-cessionnaire A pplicani-lransferee Transfert de permis Transfer of permil\t1765\t22-02-75\tM-6344\tAccordée 1 Grunted MPT-8763\t21-04-75\tM-2048I7-D-2 JEAN-NOEL GU1LBERT Requérant-cédant Applicant-transferror\t2081\t08-03-75\tM-6535\tAccordée / Granted 3798 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 \t\t\tGOO.\t\t\t \t\tRequérante Applicants\t\t\tCause\tDécisions No\tDale\t\tP»ge\tdate\tCase\t \t\tM-206228\t\t\t\t \t\tREAL CLAUDE\t\t\t\t \t\tRequeranl-cessionnaire\t\t\t\t \t\tApplicani-iransferer\t\t\t\t \t\tTransfert de permis\t\t\t\t MPT-8764\t21-04-75\tTransfer of permit M-205162-D-I RAOUL LEPAGE Requéranl-cédanl Applicant-transferror M-200024-D-2 OMAR ELMOHTASEB Requeranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis\t2081\t08-03-75\tM-6536\tAccordée / Granted MPT-8765\t21-04-75\tTransfer of permit M-203911 BENNY LANNIGAN Requérant-cédant Applicant-transferror M-206231 ERNIE DAVIS Requeranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit\t2081\t08-03-75\tM-6537\tAccordée 1 Granted MPT-8766\t21-04-75\tM-203579 AGOP MANUKYAN Requéranl-cédanl Applicant-transferror M-206241 ANTOINE EL-HELOU Requéranl-cessionnaiie Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit\t2081\t08-03-75\tM-6538\tAccordée / Granted MPT-8767\t21-04-75\tM-204918-D-I LIONEL LALANCETTE Requéranl-cédanl Applicant-transferror M-204180-D-I0 FAUCHER ENTREPRISES INC.Requeranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit\t2082\t08-03-75\tM-6539\tAccordée / Granted MPT-8768\t21-04-75\tM-204421-D-1 TAXI PEPIN INC.Requérame-cédanle Applicant-transferror M-206233 DENIS BESSETTE Requeranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit\t2082\t08-03-75\tM-6540\tAccordée / Granted MCR-1800-\t25-04-75\t524I-V-D-I-TF\t1870\t01-03-75\tM-6388\tAccordée / Granted TF\t\tE.J.PERSONS TRANSPORT LTD Modification de larif\t\t\t\t MCR-I8I0\t\tTariff modification\t\t\t\t \t25-04-75\tI3579-V-D-3\t1770\t22-02-75\tM-6390\tAccordée 1 Granted \t\tLAFORTUNE TRANSPORT LIMITEE\t\t\t\t \t\tRequérante- venderesse\t\t\t\t \t\tApplicant-vendor\t\t\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3799 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérams\t\t\tCause\t No\tDaie\t\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\tCase\t \t\tTRANSPORT LAFORTUNE (1975) LTEE\t\t\t\t \t\tRequérante-acquéreur Applicant-purchaser\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\tTransfert de permis\t\t\t\t \t\tTransfer of permil\t\t\t\t MCR-1811\t28-04-75\t24112-V-D-l ABRAHAM ABRAMOVITCH Nouvelle demande New application\t1730\t22-02-75\tM-6109\tAccordée / Granted MCR-1812\t28-04-75\t24111-V-D-l\t1379\t08-02-75\tM-5480\tAccordée / Granted MCS-1174\t\tCLAUDE BEAULIEU Nouvelle demande New application\t\t\t\t MCR-1816-\t30-04-75\t30006-D-38-TF\t2229\t15-03-75\tM-6651\tAccordée / Granted TF\t\tNIAGARA FRONTIER TARIFF BUREAU INC.Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCR-1817-\t30-04-75\t30005-D-14-TF\t2229\t15-03-75\tM-6650\tAccordée / Granted TF\t\tMIDDLE ATLANTIC CONFERENCE Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCS-1176\t29-04-75\t24058-V-D-l\t9313\t14-12-74\tM-4184\tRejetée / Rejected \t\tNELSON RANGER\t\t\t\t \t\tVoiturier-remorqueur\t\t\t\t \t\tHaulaway operator\t\t\t\t \t\tNouvelle demande\t\t\t\t \t\tNew application\t\t\t\t \t\t16057-V\t\t\t\t \t\tH.G.SNYDER TRUCKING INC.\t\t\t\t \t\tVoiturier-roulier / Carrier\t\t\t\t \t\tDroit additionnel\t\t\t\t \t\tAdditional right\t\t\t\t MCS-1178-\t29-04-75\t21031-V-D-3-TF\t1883\t01-03-75\tM-6531\tAccordée / Granted TF\t\tDAILY FREIGHT FORWARDERS LTD.Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCS-1179-\t29-04-75\t20873-V-D-3-TF\t1883\t01-03-75\tM-6530\tAccordée / Granted TF\t\tAPEX FORWARDING LIMITED Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t ML-587-\t25-04-75\t86-DY-D-4-TF\t2077\t08-03-75\tM-6515\tAccordée / Granted TF\t\tAVIS TRANSPORT OF CANADA LTD.Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t ML-588\t25-04-75\t1015-DY 620-DYV JIM PATTISON LEASE LTD.Requérante-venderesse Applicant-vendor GREAT PACIFIC INDUSTRIES LTD.Requérante-acquéreur Applicant-purchaser Transfert de permis Transfer of permil\t1752\t22-02-75\tM-6205\tAccordée / Granted ML-589\t25-04-75\t2012-DYV-D-I INDIANHEAD FINANCIAL SERVICES LIMITED Nouvelle demande New application\t996\t25-01-75\tM-5058\tAccordée / Granted ML-590\t25-04-75\t1387-DY-D-l PARC SAFARI AFRICAIN INC.Nouvelle demande New application\t1013\t25-01-75\tM-5208\tAccordée / Granted 3800 QUÊIlEC Off ICI.IL GAZETTE.May 10, 1975, Vol.107, No.19 \t\t\tG OO\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\tDécisions No\tDale\t\tpage\tdate\t\t \t\tApplicants\t\t\tCase\t MCS-1180\t29-04-75\t24103-V-D-l GARY V.MASON Voiturier-remorqueur Haulaway operator Nouvelle demande New application 659-V SMITH TRANSPORT CO.LIMITED Voilurier-roulier / Carrier Droit additionnel\t1016\t25-01-75\tM-5219\tAccordée / Granted \t\tAdditional right\t\t\t\tRejetée / Rejected MCS-II8I\t30-04-75\t16228-VM REID'S MOVING & STORAGE CO LTD Mise en cause CECIL B REID BEATRICE REID Requérantes-venderesses /fpp/icanf-irm/orj MALASPINA MOVING & STORAGE LIMITED Requérante-acquéreur Applicant-purchaser Transfert d'actions Transfer of shares\t2722\t05-05-73\t\t MCS-II82\t30-04-75\"\t24113-V-D-l ANDRE RHEAUME Nouvelle demande New application\t1389\t08-02-75\tM-6070\tAccordée / Granted MCV-4615\t25-04-75\tM-500486-D-002\t\t\tM-7063\tDéclare le dossier clos.\t\tADRIEN BERNARD\t\t\t\tDeclares ihe file closed.\t\tDemande de permis\t\t\t\t \t\tApplication for permil\t\t\t\t MCV-4616\t25-04-75\tM-500148-D-I\t\t\tM-7255\tDéclare le dossier clos.\t\tFERNAND GREGOIRE\t\t\t\tDeclares the file closed.\t\tDemande de permis\t\t\t\t \t\tApplication for permil\t\t\t\t MCV-4619\t25-04-75\tM-500866-D-9\t\t\tM-7654\tDéclare le dossier clos.\t\tDANIEL GRAHAM\t\t\t\tDeclares ihe file closed.\t\tDemande de permis\t\t\t\t \t\tApplication for permil\t\t\t\t MCV-4620\t25-04-75\tM-500866-D-013\t\t\tM-7655\tDéclare le dossier clos.\t\tDANIEL GRAHAM\t\t\t\tDeclares the file closed.\t\tDemande de permis\t\t\t\t \t\tApplication for permit\t\t\t\t MCV-4621\t25-04-75\tM-500866-D-7\t\t\tM-7656\tDéclare le dossier clos.\t\tDANIEL GRAHAM\t\t\t\tDeclares the file closed.\t\tDemande de permis\t\t\t\t \t\tApplication for permit\t\t\t\t MCV-4622\t25-04-75\tM-500866-D-I2\t\t\tM-7657\tDéclare le dossier clos.\t\tDANIEL GRAHAM\t\t\t\tDeclares the file closed.\t\tDemande de permis\t\t\t\t \t\tApplication for permit\t\t\t\t MCV-4623\t25-04-75\tM-500866-D-16\t\t\tM-7658\tDéclare le dossier clos.\t\tDANIEL GRAHAM\t\t\t\tDeclares the file closed.\t\tDemande de permis\t\t\t\t \t\tApplication for permit\t\t\t\t MCV-4624\t25-04-75\tM-500866-D-8 DANIEL GRAHAM Demande de permis Application for permil\t\t\tM-7647\tDéclare le dossier clos.Declares the file closed. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3801 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\t No\tDaie\t\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\tCase\t MCV-4625\t25-04-75\tM-500866-D-U\t\t\tM-7648\tDéclare le dossier clos.\t\tDANIEL GRAHAM\t\t\t\tDeclares the file closed.\t\tDemande de permis\t\t\t\t \t\tApplication for permit M-500866-D-15\t\t\t\t MCV-4626\t25-04-75\t\t\t\tM-7649\tDéclare le dossier clos.\t\tDANIEL GRAHAM\t\t\t\tDeclares the file closed.\t\tDemande de permis\t\t\t\t \t\tApplication for permil\t\t\t\t MCV-4627\t25-04-75\tM-50001 l-D-2 LOUIS-CYR ARCHAMBAULT Demande de permis Application for permit\t\t\tM-7520\tDéclare le dossier clos.Declares the file closed.MCV-4628\t25-04-75\tM-500866-D-IO DANIEL GRAHAM Demande de permis Application for permit\t\t\tM-7651\tDéclare le dossier clos.Declares the file closed.MCV-4629\t25-04-75\tM-500866-D-6 DANIEL GRAHAM Demande de permis Application for permit\t\t\tM-7650\tDéclare le dossier clos.Declares ihe file closed.MCV-4630\t25-04-75\tM-50O866-D-5 DANIEL GRAHAM Demande de permis Application for permil\t\t\tM-7653\tDéclare le dossier clos.Declares the file closed.MCV-4631\t25-04-75\tM-501359-D-1 EDGAR PION Demande de permis Application for permil\t\t\tM-7384\tDéclare le dossier clos.Declares ihe file closed.MCV-4632\t25-04-75\tM-500242-D-3 PERCY SUTTON Demande de permis Application for permit\t\t\tM-7399\tDéclare le dossier clos.Declares ihe file closed.MCV-4633\t25-04-75\tM-504798-D-2 RAYMOND BOUFFARD Demande de permis Application for permit\t\t\tM-7386\tDéclare le dossier clos.Declares ihe file closed.MCV-4634\t28-04-75\tM-501529-D-9 C.AUBIN EXCAVATION INC.Requérante-venderesse Appticanl-vendor M-505866-D-1 PHILIPPE PERRON Requérant-acquéreur Applicani-purchaser Transfert d'attestation\t1866\t01-03-75\tM-6333\tAccordée / Granted ML-592\t25-04-75\tTransfer of certificate I378-DY-D-1 AUTO FISKE INC.Nouvelle demande New application\t49\t04-01-75\tM-4439\tAccordée telle qu'amendée Granted as amended.ML-591\t25-04-75\t2013-DY V-D-l LOCATION SAS.INC.Nouvelle demande New applicalion\t997\t25-01-75\tM-5059\tAccordée / Granted ML-597\t29-04-75\tI397-DY-D-I 2028-DYV LOMBARDI AUTOS LTEE Nouvelle demande\t1877\t01-03-75\tM-6422\tAccordée / Granted ML-598\t29-04-75\tNew applicalion 1377-DY 2002-DY V-D-l\t48\t04-01-75\tM-4435\tAccordée telle qu'amendée \t\tLOCATION VAUDREUIL ENRG.Nouvelle demande New applicalion\t\t\t\tGranted as amended. 3802 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\tDécisions No\tDate\t\tpage\tdate\t\t \t\tApplicants\t\t\tCase\t ML-599\t29-04-75\t1396-DY 2025-DY V-D-l DUPORTAGE MERCURY VENTES LTEE Nouvelle demande New applicalion\t1862\t01-03-75\tM-6324\tAccordée / Granted ML-593\t28-04-75\t1380-DY 2005-DY V-D-l LOCATION COITEUX INC.Nouvelle demande\t130\t11-01-75\tM-4524\tAccordée / Granted \t\tNew applicalion\t\t\t\tAccordée / Granted ML-594\t28-04-75\t2020-DY V-D-l LEVERT TRANSPORT INC.Nouvelle demande\t1389\t08-02-75\tM-6069\t ML-595\t28-04-75\tNew applicalion 1307-DY 1102-DYV-D-2 DOM RENTALS (OUEBEC) INC.Changement de place d'affaires\t1729\t22-02-75\tM-6106\tAccordée / Granted ML-596\t28-04-75 A\tChange of business place.790-DY-D-l GEORGES AUBE AUTO LOCATION ENRG.Requérante-venderesse Applicant-vendor GEORGES AUBE AUTO LOCATION ENRG.Requéranle-acquéreur Applicant-purchaser Transfer! de permis\t1364\t08-02-75\tM-5406\tAccordée / Granted \t\tTransfer of permil\t\t\t\tAccordée / Granted OCR-1012-\t24-04-75\t4545-V-D-3-TF\t1720\t22-02-75\tQ-2936\t TF\t\tTRANSPORT LA VOIE LTEE Modification de tarifs Tariffs modification\t\t\t\t OCR-1013\t24-04-75\t24130-V-D-l\t1570\t15-02-75\tQ-2913\tAccordée / Granted \t\tMAURICE THERRIEN\t\t\t\t QCR-1014\t24-04-75\t15-V-D-I7 TRANSPORT D'ANJOU INC.Modification de permis Modification of permil\t1570\t15-02-75\t0-2911\tAccordée / Granted OCR-1019\t25-04-75\t18349-V-D-l MAURICE GUILLEMETTE INC.Modification de permis Modification of permit\t1571\t15-02-75\t0-2915\tAccordée / Granted OCR-1020\t25-04-75\t1824-V-D-l LE DEMENAGEUR QUEBECOIS LTEE\t1572\t15-02-75\t0-2916\tAccordée / Granted OCR-1021\t25-04-75\t21093-V-D-4 L.B1LODEAU ET FILS LTEE Modification de permis Modification of permil\t1569\t15-02-75\tQ-2910\tAccordée / Granted OCR-1022-\t28-04-75\t13605-V-D-l-TF\t1719\t22-02-75\t0-2928\tAccordée / Granted TF\t\tLES DEMENAGEMENTS COTE JUNIOR\t\t\t\t \t\tENR.\t\t\t\t \t\t(Yves Côté Junior),\t\t\t\t \t\tModification de tarifs\t\t\t\t \t\tTariffs modification\t\t\t\t OCR-1024\t28-04-75\t23048-V-D-2\t1848\t01-03-75\tQ-2982\tAccordée / Granted \t\tEXPRESS C.T.M.A.LTEE\t\t\t\t \t\tC.T.M.A.EXPRESS LTD.\t\t\t\t \t\tDroit additionnel\t\t\t\t \t\tAdditional right\t\t\t\t OCR-1025\t28-04-75\t18309-V-D-l\t1849\t01-03-75\t0-2985\tAccordée / Granted \t\tSYLVIO PROTEAU\t\t\t\t \t\tModification de permis\t\t\t\t \t\tModification of permil\t\t\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3803 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\t No\tDale\t\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\tCase\t OCR-1026\t28-04-75\t24I65-V-D-1 MARCEL BELANGER\t2222\t15-03-75\t0-3135\tAccordée / Granted OCR-1027\t29-04-75\t4281-V-D-2\t141\t11-01-75\tQ-2704\tAccordée en partie \t\tTRANSPORT ARMAND ALLAIRE LTEE\t\t\t\tPartly granted \t\tModification de permis\t\t\t\t \t\tModification of permit\t\t\t\t OCR-1028-\t29-04-75\t17669-V-D-2-TF\t1718\t22-02-75\tQ-2926\tAccordée / Granted TF\t\tAIR CARGO SERVICE (SEPT-ILES) INC.Modification de tarifs Tariffs modification\t\t\t\t OCR-1029\t29-04-75\t3713-V-D-l ERNEST LAMOTHE & FILS INC.Transfert d'actions Transfer of shares\t43\t04-01-75\tQ-2655\tAccordée / Granted OCR-1030-\t30-04-75\t14256-V-D-I-TF\t1568\t15-02-75\tQ-2906\tAccordée / Granted TF\t\tGASPE EQUIPMENT ET TRANSPORT CIE LTEE Modification de tarifs Tariffs modification\t\t\t\t OCR-1031-\t30-04-75\tI0814-V-D-I-TF\t2064\t08-03-75\tQ-3041\tAccordée / Granted TF\t\tTRANSPORT CLERMONT INC.Modification de tarifs Tariffs modification\t\t\t\t OCR-1032\t01-05-75\t24045-V-D-l TRANSPORT DIONNE LTEE\t137\t11-01-75\tQ-2690\tAccordée / Granted OCS-552\t24-04-75\t127I-V-D-1 DAME ANNA DESCHENE-FRENETTE\t2089\t08-03-75\tQ-3115\tAccordée / Granted \t\t(ès-qualité de légataire universelle / In her\t\t\t\t \t\tcapacity of universal legatee)\t\t\t\t \t\tLAUREAT FRENETTE\t\t\t\t \t\tRequérante-cédante\t\t\t\t \t\tApplicant-transferror\t\t\t\t \t\t22890-V\t\t\t\t \t\tCHARLES-HENRI ROY\t\t\t\t \t\tRequérant-cessionnaire\t\t\t\t \t\tApplicant-transferee\t\t\t\t \t\tTransfert de permis\t\t\t\t \t\tTransfer of permit\t\t\t\t QCS-553\t24-04-75\t31I1-V-D-4 PIUZE TRANSPORT INC.Modification de permis Modification of permit\t1722\t22-02-75\tQ-2941\tAccordée / Granted OCS-554\t24-04-75\t2951-V-D-3 JEAN COTE Requérant-cédant Applicant-transferror TRANSPORT JEAN COTE LTEE Requérante-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis\t1773\t22-02-75\tO-2980\tAccordée / Granted \t\tTransfer of permil\t\t\t\tAccordée / Grunted OCS-555\t25-04-75\t24I34-V-D-I LEONARD LOISEL ET FILS ENRG.\t1571\t15-02-7?\tQ-2914\t \t\t(Léonard Loisel et land Aldège Loisel)\t\t\t\tAccordée / Granted OCS-558\t30-04-75\t23I84-V-D-1 ANDRE LALIBERTE Voiturier-remorqueur Haulaway operator 2262 l-V JEAN-MARIE GOSSELIN & FILS Voiturier-roulier / Carrier\t8850\t23-11-74\t0-2371\t 3804 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May JO, J975, Vol.107, No.J9 \t\t\tGOO.\t\t\t \t\tRequérants Applicants\t\t\tCause\tDécisions No\tDale\t\tpage\tdate\tCase\t OPV-458-\t28-04-75\t3372-A-D-l-TF\t2066\t08-03-75\tO-3050\tAccordée / Granted TF\t\tTRANSPORT SECURITAIRE ST-PROSPER INC.Modificalion de larifs Tariffs modification\t\t\t\t QPV-459-\t28-04-75\t97-A-D-8-TF\t2066\t08-03-75\tO-305I\tAccordée / Granted TF\t\tAUTOBUS DRUMMONDVILLE LTEE Modificalion de tarifs Tariffs modification\t\t\t\t OPV-460-S\t28-04-75\t3422-A-D-4 JEAN-MARC OUELLET\t1848\t01-03-75\t0-2984\tAccordée / Granted QL-263\t25-04-75\t1394-DY & 2023-DYV-D-l\t1573\t15-02-75\t0-2924\tAccordée / Granted \t\tLOCATION FOURNIER INC\t\t\t\tAccordée / Granted QL-264\t28-04-75\tI398-DY-D-1\t1850\t01-03-75\tO-300I\t \t\tDROUIN AUTOMOBILES LTEE\t\t\t\t OL-265\t28-04-75\t1261-DY & 2034-DYV-D-2 LAURIER AUTO INC.Modification de permis\t2220\t15-03-75\t0-3106\tAccordée / Granted \t\tModification of permil\t\t\t\tAccordée / Granted QL-266-TF\t30-04-75\t64I-DY-D-1-TF THETFORD RENT-A-CAR INC.Modification de tarifs Modification of tariffs\t1568\t15-02-75\t0-2909\t QL267\t30-04-75\tI258-DY-D-2\t45\t04-01-75\t0-2665\tAccordée / Granted \t\tJACOUES GIRARD AUTOMOBILES INC.Requérante-venderesse Applicant-vendor LOCATION D'AUTOMOBILES JACOUES GIRARD INC.Requérante-acquéreur Applicant-purchaser Transfert de permis Transfer of permit\t\t\t\t QL-268\t01-05-75\tI0I9-DY & 94I-DYV-D-1 LOCATION D'AUTOS SIROIS INC.Modificalion de permis Modification of permit\t5926\t24-08-75\t0-1593\tAccordée / Granted QL-269\t01-05-75\t1382-DY-D-l TRACADIECHE AUTOMOBILES INC\t140\t11-01-75\tO-270I\tAccordée / Granted OCV-2221\t25-04-75\tQ-50I925-D-00I MME THERESE LESAGE Requérante-cédante Applicant-transferror O-504782-D-00I RENAUD PAULIN Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit\t1394\t08-02-75\t0-2922\tAccordée / Granted OCV-2222\t28-04-75\tO-503444-D-002\t\t\tQV-3828\tDésistement \t\tLEONCE BEAUDIN\t\t\t\tWithdrawal OCV-2225\t28-04-75\tO-502684-D-00I\t2539\t22-03-75\t0-3198\tAccordée / Granted \t\tFRANÇOIS LARIVIERE\t\t\t\t \t\tRequéranl-cédanl\t\t\t\t \t\tApplicant-transferror\t\t\t\t \t\tO-5048I4-D-001\t\t\t\t \t\tGASTON ST-PIERRE\t\t\t\t \t\tRequérant-cessionnaire\t\t\t\t \t\tApplicant-transferee\t\t\t\t \t\tTransfert d'attestation\t\t\t\t \t\tTransfer of certificate\t\t\t\t OCV-2226\t29-04-75\tO-502203-D-00I MAURICE BLOUIN\t\t\tQV-746\tRejetée / Rejected GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1915, JOT année, n° 19 3805 \t\t\tG.O.O.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\t No\tDaie\t\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\tCase\t OCV-2227\t30-04-75\tQ-50I624-D-001\t1361\t08-02-75\tQ-2849\tAccordée / Granted \t\tROGER ROCHELEAU\t\t\t\t \t\tRequérant-cédant\t\t\t\t \t\tApplicam-lransferror\t\t\t\t \t\tQ-504735-D-001\t\t\t\t \t\tPAUL-EMILE LA VOIE\t\t\t\t \t\tRequérant-cessionnaire\t\t\t\t \t\tApplicant-transferee\t\t\t\t \t\tTransfert de permis\t\t\t\t \t\tTransfer of permit\t\t\t\t QCV-2228\t30-04-75\tO-5007I1-D-001 PAUL-EMILE GUILBEAULT Requérant-cédant Applicant-transferror O-504792-D-001 ADELARD DORION Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permil\t1393\t08-02-75\tQ-2895\tAccordée / Granted OCV-2229\t01-05-75\tO-503581-D-001 MME PAUL CAMPION Requérante-cédanle Applicant-transferror Q-504801-D-001 GERARD CAMPION Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert d'attestation Transfer of certificate\t2538\t22-03-75\t0-2942\tAccordée / Granted OPT-3122\t25-04-75\tQ-202036\t\t\t0-2414\tRejetée / Rejected \t\tADOLPHE NOEL\t\t\t\t OPT-3123\t25-04-75\tQ-201898 BENOIT ST-ONGE\t\t\tQ-2415\tRejetée / Rejected OPT-3127\t30-04-75\tQ-200074 PAUL RUEL Requérant-cédant Applicant-transferror Q-202169 GILLES TARDIF Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permil\t2540\t22-03-75\tQ-3207\tAccordée / Granted QPT-3128\t30-04-75\tQ-202151 ROGER RICHARD\t2533\t22-03-75\t0-3162\tAccordée / Granted QPT-3129\t30-04-75\tO-201024-D-001 REAL CLAVEAU Requérant-cédant Applicant-transferror Q-202167-D-I SARTO TREMBLAY Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit\t2540\t22-03-75\tQ-3210\tAccordée / Granted QPT-3130\t30-04-75\tO-201024-D-2 REAL CLAVEAU Requérant-cédant Applicant-transferror O-202167-D-2 SARTO TREMBLAY Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit\t2539\t22-03-75\tQ-3209\tAccordée / Granted 3806 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequéranls\t\t\tCause\tDécisions No\tDale\t\tpage\tdale\t\t \t\tApplicants\t\t\tCase\t QPT-3131\t30-04-75\tQ-201580 MME ANNETTE L.BLA1S Requéranie-cédanle Applicant-transferror 0-202170 EDOUARD ST-GERMAIN Requeranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis\t2539\t22-03-75\tO-3206\tAccordée / Granted QPT-3132\t30-04-75\tTransfer of permit O-201451 FLORENT CLAVEAU Requéranl-cédan! Applicant-transferror Q-202168 GERVAIS TREMBLAY Requeranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis\t2539\t22-03-75\tO-3208\tAccordée / Granted \t\tTransfer of permit\t\t\t\tAccordée / Granted OPT-3133\t30-04-75\tQ-201666 J.B.WILFRID DIONNE Requéranl-cédan! Applicant-transferror O-202171 JACOUES LABBE Requeranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfer! de permis Transfer of permil\t2539\t22-03-75\tO-3205\t SEANCES EN CHAMBRES \u2014 TRANSPORT PAR VEHICULE-TAXI SITTINGS IN CHAMBERS \u2014 TRANSPORT BY TAXICAB _ No\tDale\tRequéranl Applicant\tC Ap Calégorie Class\temande de plication for Aggl.Congl.\t>ermis permit Région\tCause Case\tDécision QPT-2475\t30-04-75\tO-201752-D-1\tOrdinaire Ordinary\tA-36\tQuébec\tOT-2416\tAccordée Granted PERMIS SPECIAUX I SPECIAL PERMITS No du répenoire chronologique\tNom du requérant\tPériode validité Chronological Repertory No.\tName of Applicant\tPeriod of validity MS-1434\t24208-V-S-l MRS-0992 LA LIGUE DES TAXIS DE ST-JEROME INC.\t Détails de la demande et de la décision: Particulars of applicalion and decision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» les 4, 5, 6.mars Applicalion published in Ihe newspaper \"Le Devoir\" March 1975.4, 5.6, 1975.Rejelée.Rejected.\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3807 No du répertoire\t\t chronologique\tNom du requérant\tPériode de validité Chronological\tName of Applicant\tPeriod of validity Repertory No.\t\t MS-1435\t197-V-S-2 MRS-0953\t \tST-JACQUES EXPRESS ENRG.\t Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 28 février 1975, le 1er et 3 mars 1975.Rejetée.MS-1436 1550-V-S-3 MRS-1019 H.LAPALME TRANSPORT LTEE Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Journal de Montréal» les 12, 13.14.avril 1975.Rejetée.MS-I437 224I4-V-S-I MRS-0881 JEAN-MARIE PITRE Voiturier-remorqueur Haulaway operator 16057-V H .G.SNYDER TRUCKING Voiturier-roulier / Carrier Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Montréal Matin» les 12.13, 14 janvier 1975.Accordée.MS-1438 988-V-S-l MRS-1016 I BELL TRUCK CARTAGE LTD.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «La Presse» les 8.9.10 avril 1975.Rejetée.MS-1439 Particulars of application and decision: Application published in the newspaper \"Le Devoir\" February 28, 1975.March 1st and 3rd, 1975.Rejected.Particulars of application and decision: Application published in the newspaper \"Journal de Montréal\" April 12, 13, 14, 1975.Rejected.Du 10 février 1975 au 9 février 1976 ou décision finale.I From February 10, 1975 to February 9.1976 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the newspaper \"Montréal Malin\" January 12, 13.14.1975.Granted.Particulars of application and decision: Applicalion published in the newspaper \"La Presse\" April 8.9, 10.1975.Rejected.22406-V-S-2 MRS-1013 NESEL FAST FREIGHT INCORPORATED Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» les 4.7, 8.avril 1975.Rejetée.Particulars of application and decision: Applicalion published in the newspaper \"Le Devoir\" April 4.7, 8.1975.Rejected.MS-1444 24206-V-S-1 MRS-0993 ANDRE BOURDON Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Montréal Matin» les 13, 14, 15 novembre 1974.Accordée.MS-1449 15459-VM UNICUME STORAGE CO.LTD.Détails de la demande et de la décision: Permis instanter en venu de l'article 2.75 du règlement no 2.Accordée.MS-1443-S 2957-A-S-5 MRS-1006 RIVERAINS TRANSPORT INC.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» les 2, 3, 4, avril 1975.Accordée.Du 16 avril 1975 au 15 avril 1976 ou décision finale.From April 16.1975 to April 15.1976 or final decision.Particulars of applicalion and decision: Application published in Ihe newspaper \"Montréal Matin\" November 13, 14, 15, 1974.Granted.Le 24 avril 1975./April 24.1975.Particulars of application and decision: Immediate permit in virtue of section 2.75 of Regulation No.2.Granted.Du 26 juin 1975 au 23 août 1975.I From June 26.1975 to August 23.1975.Particulars of application and decision: Application published in \"Le Devoir\" April 2.3, 4, 1975.Granted. 3808 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May JO, 1975, Vol.107, No.19 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.\tNom du requérant Name of Applicant\tPériode de validité Period of validity MS-1440 Détails de la derrt Demande parue c 1975.Accordée.\t2656-V-S-9 MRS-I0I7 URGEL CHARhllb TRANSPORT LIMITEE ande et de la décision: Particul ans le journal «La Presse» les 2, 3.5, avril Applica Granted\tDu 21 avril 1975 au 21 octobre 1975 ou décision finale./ From April 21.1975 to October 21.1975 or final decision.rs of applicalion and decision: ion published in '\"La Presse\" April 2, 3, 5, 1975.MS-1441 242IO-V-S-I MRS-1008 HAROLD G.BLAKELY Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Journal de Montréal» les 28.29.30 mars 1975.Accordée.MS-1445 M-206361-S-2 MRS-1004 LIONEL BOUCHARD Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Montréal Matin» les 3, 4, avril 1975.Accordée.MS-1446 M-20636I-S-3 MRS-1005 LIONEL BOUCHARD Détails de la demande ei de la décision: Demande parue dans le journal «Montréal Matin» les 3, 4, 5 avril 1975.Accordée.MS-1447 M-206361-S-I MRS-1003 LIONEL BOUCHARD Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal «Montréal Malin» les 3.4.avril 1975.Accordée.MS-1448 22752-V-S-2 MRS-1021 DROLET TRANSPORT INC.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Journal de Montréal» les 9.10, Il avril 1975.Accordée.MS-1450 I M-503526-A-001 MRS-0998 | MICHEL FOREST Détails de la demande el de la décision: Demande de permis addilif pour le camionnag en vrac.Désistement.MS-1451 1978-A-S-l MRS-1018 | TERREBONNE AUTOBUS INC.Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal «Montréal Matin» les 8, 9.10 avril 1975.Rejelée.Du 25 avril 1975 au 24 avril 1976 ou décision finale.From April 25.1975 to April 24.1976 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in \"Journal de Montréal\" March 28, 29, 30, 1975.Granted.Du 17 avril 1975 au 16 avril 1976 ou décision finale.From April 17.1975 to April 16.1976 or final decision.Particulars of application and decision: Applicalion published in \"Montréal Matin\" April 3, 4, 5, 1975.Granted.Du 17 avril 1975 au 16 avril 1976 ou décision finale.From April 17.1975 to April 16.1976 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in \"Montréal Matin\" April 3, 4, 5, 1975.Granted.Du 17 avril 1975 au 16 avril 1976 ou décision finale.From April 17.1975 to April 16.1976 or final decision.Particulars of applicalion and decision: Application published in \"Montréal Matin\" April 3, 4, 5, 1975.Granted.Du 25 avril 1975 au 5 mai 1975 et du 25 juin 1975 au 5 juillet 1975.I From April 25.1975 to May 5.1975 and June 25.1975 to July 5.1975.Particulars of applicalion and decision: Applicalion published in \"Journal de Montréal\" April 9, 10.II.1975.Granted.Particulars of applicalion and decision: Application for additional permil for bulk trucking.Withdrawal.Particulars of application and decision: l975PPliCal'0n published in \"Mon,r«al Matin\" April 8.9.10.Rejected. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3809 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Période de validité Period of validity MS-1452 23637-V-S-1 MRS-0985 ROGER BACHAND Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «La Voix de l'Est» les 10.11.12 mars 1975.Accordée.MS-1453 22315-V-S-2 MRS-1023 OUTREMONT EXPRESS INC.Voiturier-remorqueur Haulaway operator 3653-V THETFORD TRANSPORT LTEE Voiturier-roulier / Carrier Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» les 26, 27.29 mars 1975.Accordée.OS-916\u2014TF Du 18 avril 1975 au 18 décembre 1975.I From April 18.1975 to December IS.1975.Particulars of application and decision: Application published in \"La Voix de l'Est\" March 10.11.12.1975.Granted.Du 24 avril 1975 au 23 avril 1976 ou décision finale.From April 24.1975 to April 23.1976 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in \"Lc Devoir\" March 26.27, 29.1975.Granted.346-A-MTF-l Cause: 0-941 LA COMPAGNIE DE TRANSPORT ST-MAURICE Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Nouvelliste» les 4, 7 et 8 avril 1975.Accordée.Lc présent permises! valide jusqu'au 7 novembre 1975 ou décision sur la requèle de permis régulier quel qu'en soi! le premier./ The present permil shall be valid until November 7.1975 or until the date on which a decision is rendered whichever occurs first.Particulars of applicalion and decision: Applicalion published in \"Le Nouvelliste\" on April 4th.7th and 8th.1975.Granted.OS-917 8448-V-S-1 Cause: 0-943 GLENGARRY TRANSPORT (QUEBEC) LTEE GLENGARRY TRANSPORT (QUEBEC) LTD Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «La Presse» les 10, 11 et 12 avril 1975.Rejetée.Particulars of application and decision: Applicalion published in \"La Presse\" on April 10lh.Ilth and 12th.1975.Rejected.QS-918 69-V-S-3 Cause: 0-942 BOURRET TRANSPORT LTEE Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «La Tribune» les 14.15 et 16 avril 1975.Rejetée.OS-919 2495-A-S-l Cause: Q-930 MAJELLA PAQUET INC.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 14, 15 el 16 avril 1975.Rejetée.Particulars of applicalion and decision: Application published in \"La Tribune\" on April 14th.I5th and 16lh, 1975.Rejected.Particulars of application and decision: Application published in \"Le Soleil\"\" on April 14th.15lh and 16th, 1975.Rejected.QS-920 515-V-S-2 Cause: Q-933 BECANCOUR EXPRESS TRANSPORT INC.Voiturier-remorqueur Haulaway operator Ce permis est valide jusqu'au 31 décembre 1975, ou jusqu'à décision finale de la Commission, suivant l'éventualité qui se présentera la première./This permil is valid until December 31.1975 pending final decision by the Commission whichever occurs first. 3810 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Période de validité Period of validity 312-V HAMEL TRANSPORT LOTBINIERE LTEE Voiturier-roulier / Carrier Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» les 4.7 et 8 avril 1975.Accordée.QS-921 Particulars of applicalion and decision: Application published in \"Le Devoir\" on April 4lh, 7th and 8lh.1975.Granted.312-V-S-l Cause: Q-0932 HAMEL TRANSPORT LOTBINIERE LTEE Voiturier-remorqueur Haulaway operator 5I5-V-S-2 BECANCOUR EXPRESS TRANSPORT INC.Voiturier-roulier / Carrier Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Devoir» les 4, 7 et 8 avril 1975.Accordée.Ce permis est valide jusqu'au 31 décembre 1975, ou jusqu'à décision finale de la Commission, suivant l'éventualité qui se présentera la première./ This permit is valid until December 31, 1975 pending final decision by the Commission whichever occurs first.Particulars of application and decision: Application published in \"Le Devoir\" on April 4, 7 and 8th, 1975.Granted.QS-922 Q-504439-S-001 Cause: Q-0944 JEAN-LOUIS LEMIEUX Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal «Le Jour» les 13, 14 et 15 mars 1975.Rejetée.QS-923 Q-504962-S-00I Cause: Q-0945 ALAIN GAGNON Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal «Le Jour» les 13, 14 et 15 mars 1975.Rejetée.OS-924-TF 53-A-MTF-3 Cause: Q-0899 AUTOBUS ALPHONSE DROLET LTEE Modifications de tarifs Tariffs modification Détails de la demande cl de la décision: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 24, 25 el 26 mars 1975.Accordée.QS-925 24230-V-S-1 Cause: Q-0946 BERTRAND GAGNON Voiturier-remorqueur Haulaway operator 4724-V MAGNY TRANSPORT (INCORPORE) Voiturier-roulier / Carrier Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 22, 23 et 24 avril 1975.Accordée.Particulars of applicalion and decision: Applicalion published in \"Le Jour\" on March 13, 14 and I5lh, 1975.Rejected.Particulars of application and decision: Applicalion published in \"Le Jour\" on March 13, 14 and 15th.1975.Rejected.Pour la période se terminant le 30 septembre 1975.For the période ending September 30.1975.Particulars of application and decision: Applicalion published in \"Le Soleil\" on March 24, 25 and 26th, 1975.Granted.Ce permis est valide jusqu'au 29 octobre 1975 ou jusqu'à décision finale de la Commission, suivant l'éventualité qui se présentera la première./ This permit is valid until October 29th.1975 pending final decision by the Commission whichever occurs first.Particulars of application and decision: Application published in \"Le Soleil\" on April 22, 23 and 24th.1975.Granted. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1975, 107' année, n° 19 Vil No du repertoire\t\t chronologique\tNom du requérani\tPériode de validité Chronological\tName of Applicant\tPeriod of validity Repertory No.\t\t QS-926\tQ-50III7-S-2\t \tCause: Q-0948\t \tALLEN DUMARESQ\t Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 19.21 el 22 avril 1975.Rejetée.OS-927 3406-AS-1 Cause: Q-0951 BERNARD BOULIANNE Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal .Le Soleil» les 10.Il et 12 avril 1975.Rejetée.QS-928 Q-502841-S-002 Cause: Q-0952 GASTON CLOUTIER Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 23.24 el 25 avril 1975.Rejetée.QS-929 Particulars of application and decision: Application published in \"Le Soleil\" on April 19.21 and 22nd.1975.Rejected.Particulars of applicalion and decision: Applicalion published in \"Le Soleil\" on April 10.II and 12th.1975.Rejected.Particulars of application and decision: Application published in \"Le Soleil\" on April 23.24 and 25th, 1975.Rejected.15908-V-S-1 Cause: Q-0874 ] LA CIE DE TRANSPORT RICHARD INC Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Journal de Québec» les 11.12 et 13 mars 1975.Rejetée.Particulars of applicalion and decision: Applicalion published in \"Journal de Québec\" on March II.12 and !3th.1975.Rejected.QS-930 24225-V-S-1 Cause: Q-0950 MARC LAMONDE Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans te journal «Journal de Québec» les 19, 20 el 21 mars 1975.Rejetée.QS-931 20395-V-S-1 Cause: Q-0955 ROSAIRE GAGNON Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 22, 23 el 24 avril 1975.Accordée.Particulars of application and decision: Application published in \"Journal de Québec\" on March 19.20 and 21st.1975.Rejected.Ce permis est valide jusqu'au 30 octobre 1975 ou jusqu'à décision finale de la Commission, suivant l'éventualité qui se présentera la première./ This permil is valid until October 30th.1975 pending final decision by the Commission whichever occurs first.Particulars of application and decision: Applicalion published in \"Le Soleil\" on April 22.23 and 24th.1975.Granted.60759-O 3812 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Leon Baldwin Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1566 du 23 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Leon Simon Souillac en celui de Leon Baldwin.Québec, le 28 avril 1975.Le sou.i-vtini.ilre de la justice, 60782-o Robert Normand, c.r.Horace Roger Adélard Bélanger Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1510 du 16 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Horace Roger Adélard Gariépy en celui de Horace Roger Adélard Bélanger.Québec, le 23 avril 1975.Le sous-minislre de la justice, 60782-o Robert Normand, ch.Marie Ginette Lise Branchatid II a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1571 du 23 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Marie Ginette Louise liranchaud en celui de Marie Ginette Lise Branchaud.Québec, le 28 avril 1975.Le sous-minislre de la justice, 60782-o Robert Normand, c.r.Arnold Chicquin Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1573 du 23 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Arnold Strong en celui de Arnold Chicquin.Québec, le 28 avril 1975.Le sous-ministre de la justice, 60782-o Robert Normand, c.r.Claude Côté Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1513 du 16 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Joseph Roger Jean Claude en celui de Claude Côté.Québec, le 23 avril 1975.Le sous-ministre de la justice, 60782-o Robert Normand, c.r.Joseph Reynald Daniel Danis Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1569 du 23 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Joseph Reynald Daniel Proulx en celui de Joseph Reynald Daniel Danis.Québec, le 28 avril 1975.Le sous-ministre de la justice, 60782-o Robert Normand, c.r.Change of name \u2014 Act Granted Leon Baldwin It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Leon Simon Souillac to that of Leon Baldwin, by order number 1566, dated April 23, 1975.Québec, April 28, 1975.Robert Normand, q.c, 60782 Deputy Minister of Justice.Horace Roger Adélard Bélanger It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Horace Roger Adélard Gariépy to that of Horace Roger Adélard Bélanger, bv order number 1510, dated April 16, 1975.Québec, April 23, 1975.Robert Normand, q.c, 60782 Deputy Minister of Justice.Marie Ginette Lise Branchaud It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Ginette Louise Branchaud to that of Marie Ginette Lise Branchaud, by order number 1571, dated April 23, 1975.Québec, April 28, 1975.Robert Normand, q.c, 60782 Deputy M in ister of Justice.Arnold Chicquin It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Arnold Strong to that of Arnold Chicquin, by order number 1573, dated April 23, 1975.Québec, April 28, 1975.Robert Normand, q.c, 60782 Deputy Minister of Justice.Claude Côté It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change t he name of Joseph Roger Jean Claude to that of Claude Côté, by order number 1513, dated April 16, 1975.Quebec, April 23, 1975.Robert Normand, q.c., 60782 Deputy Minister of Justice.Joseph Reynald Daniel Danis It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Reynald Daniel Proulx to that of Joseph Reynald Daniel Danis, by order number 1569, elated April 23,1975.Québec, April 28.1975.Robert Normand, q.c, 60782 Deputy Minister of Justice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3813 Sulaiman Mohamed Essop Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1512 du 16 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Sulayman Essop Mohamed en celui de Sulaiman Mohamed Essop.Québec, le 23 avril 1975.Le sous-minislre de la justice, 60782-o Robert Normand, c.r.Marie Marguerite Nicole Gosselin Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1572 du 23 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Marie Marguerite Nicole Du-chaine en celui de Marie Marguerite Nicole Gosselin.Québec, le 28 avril 1975.Le sous-ministre de la justice, 60782-o Robert Normand, c.r.Sulaiman Mohamed Essop It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Sulayman Essop Mohamed to that of Sulaiman Mohamed Essop, by order number 1512.dated April 16.1975.Québec, April 23, 1975.Robert Normand, q.c., 60782 Deputy Minister of Justice.Marie Marguerite Nicole Gosselin It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Marguerite Nicole Du-chaine to that of Marie Marguerite Nicole Gosselin, by order number 1572, dated April 23,1975.Québec, April 28, 1975.Robert Normand, q.c, 60782 Deputy Minister of Justice.Marguerite Marie Irene Francoeur Guillemette Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1509 du 16 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Marguerite-Marie-Irène Francoeur en celui de Marguerite Marie Irène Francoeur Guillemette.Québec, le 23 avril 1975.Le sous-minislre de la justice, 60782-o Robert Normand, c.r.Marguerite Marie Irène Francoeur Guillemette It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marguerite-Marie-Irène Francoeur to that of Marguerite Marie Irène Francoeur Guillemette, by order number 1509, dated April 16, 1975.Québec, April 23, 1975.Robert Normand, q.c, 60782 Deputy Minister of Justice.Gan Wo Hum Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1565 du 23 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Shou Park (Henry) Wong en celui de Gan Wo Hum.Québec, le 28 avril 1975.Le sous-ministre de la justice, 60782-o Robert Normand, c.r.Gan Wo Hum it has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Shou Park (Henry) Wong to that of Gan Wo Hum, by order number 1565, dated April 23, 1975.Québec, April 28, 1975.Robert Normand, q.c, 60782 Deputy Minister of Justice.Edward Juzalaitis Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1511 du 16 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Edward Juziliastis en celui de Edward Juzalaitis.Québec, le 23 avril 1975.Le sous-minislre de la justice, 60782-o Robert Normand, c.r.Edward Juzalaitis It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Edward Juziliastis to that of Edward Juzalaitis, by order number 1511, dated April 16, 1975.Québec, April 23, 1975.Robert Normand, q.c, 60782 Deputy Minister of Justice.Michael Kaud Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1568 du 23 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Mahmud Abu-Kaud en celui de Michael Kaud.Québec, le 28 avril 1975.Le sous-minislre de la justice.60782-o Robert Normand, c.r.Michael Kaud It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Mahmud Abu-Kaud to that of Michael Kaud, by order number 1568, dated April 23, 1975.Québec.April 28, 1975.Robert Normand, q.c, 60782 Deputy Minister of Justice. 3814 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Marie Antonia Yvette Mathé Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1570 du 23 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Marie Antonia Mathé en celui de Marie Antonia Yvette Mathé.Québec, le 28 avril 1975.Le sous-ministre de la justice, 60782-o Robert Normand, c.r.Marie Antonia Yvette Mathé It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Antonia Mathé to that of Marie Antonia Yvette Mathé, by order number 1570, dated April 23, 1975.Québec, April 28, 1975.Robert Normand, q.c, 60782 Deputy Minister of Justice.Ray Thomas Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1574 du 23 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Thomas Raymond Wheeler en celui de Ray Thomas.Québec, le 28 avril 1975.Le sous-ministre de la justice, 60782-o Robert Normand, c.r.Joseph George Dennis Vital Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1567 du 23 avril 1975 d'effectuer le changement de nom de Joseph George Denis en celui de Joseph George Dennis Vital.Québec, le 28 avril 1975.60782-o Le sous-ministre de la justice.Robert Normand, c.r.Ray Thomas It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Thomas Raymond Wheeler to that of Ray Thomas, by order number 1574, dated April 23, 1975.Québec, April 28, 1975.Robert Normand, q.c, 60782 Deputy Minister of Justice.Joseph George Dennis Vital It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph George Denis to that of Joseph George Dennis Vital, by order number 1567, dated April 23, 1975.Québec, April 28, 1975.60782 Robert Normand, q.c.Deputy Minister of Justice.Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Change of name Applications Act Eva Barton Avis est donné par la présente que Dame Éva Barton, domiciliée et résidant au 1545, avenue MacGregoi, appartement 904, en les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Dame Éva Vézina.Montréal, le 25 mars 1975.60717-18-2-o Le procureur de la requérante, Cyril E.Schwisberg.Solika Zini Avis est donné que dame Solika Zini, majeure, secrétaire, divorcée, demeurant au numéro 3170, Goyer, appartement 14, en les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin que son nom soit changé de Solika Zini en celui de Solange Zini.Montréal, le 11 avril 1975.La requérante, 60718-18-2 Solika Zini.Eva Barton Notice is hereby given that Dame Eva Barton, domiciled and residing in the City and District of Montreal at 1545 MacGregor Avenue, Apartment 904, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the adoption of an order changing her name from Dame Éva Barton to Dame Éva Vézina.Montreal, March 25, 1975.60717-18-2-0 Cyril E.Schwisberg, Attorney for the petitioner.Solika Zini Take notice that Dame Solika Zini, major, secretary, divorced, residing at 3170 Goyer, Apartment 14, in the City and District of Montreal, will petition the Lieutenant-Governor in Council in order to have her name changed from Solika Zini to Solange Zini.Montreal, April 11, 1975.\u201e Solika Zini, 60718-18-2-o Petitioner. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3815 André Boosamra Avis est par les présentes donné que André Boosamra, domicilié au 71, 7e Rue ouest, Ste-Anne-des-Monts, district de Gaspé, province de Québec, déposera auprès du ministre de la Justice une requête afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de André Gauthier.Ste-Anne-des-Monts, ce 2e jour d'avril 1975.60784-19-2-o André Boosamra.André Boosamra Notice is hereby given that André Boosamra, residing and domiciled at 71, 7th Street West in Ste-Anne-des-Monts, district of Gaspé, Province of Québec, will apply to the Minister of Justice for an order changing his name to André Gauthier.Ste-Anne-des-Monts, April 2th, 1975.60784-19-2-o André Boosamra.Joseph-Gonzague-Jacques Boulianne Avis est donné que Jacques Boulianne domicilié au 12 rue Laval, Québec, a déposé une requête auprès du ministre de la Justice de la province de Québec pour obtenir un décret changeant son nom de Joseph-Gonzague-Jacques Boulianne en celui de Jack Browning.Québec, ce 10 mars 1975.Les procureurs du requérant, 60785-19-2-o Sirois, Laperrière & Lemire.Joseph-Gonzague-Jacques Boulianne Notice is hereby given that Jacques Boulianne, domiciled at 12, Laval Street, Québec, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec for an order changing his name to that of Jack Browning.Québec, March 10, 1975.Sirois, Laperrière & Lemire, 60785-19-2-o Attorneys for the petitioner.Joseph Ernest Danville Leroux Avis est par les présentes donné que Joseph Ernest Danville Leroux, présentement domicilié au 160 rue Baribeau, Gatineau, province de Québec, entend présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Joseph Ernest Daniel Leroux.Hull, le 22 avril 1975.Le procureur du requérant, 60786-19-2-o Me Daniel Gervais.Joseph Ernest Danville Leroux Notice is hereby given that Joseph Ernest Danville Leroux, presently domiciled at 160 Baribeau Street, Gatineau, Province of Québec, intends to present a petition to the Lieutenant-Governor in Council in order to obtain a decree permitting him to change his name to Joseph Ernest Daniel Leroux.Hull, April 22, 1975.Me Daniel Gervais, 60786-19-2-o Attorney for the pétitionner.David Michael Darwin McDonald Avis est donné par les présentes que David Michael Darwin McDonald, domicilié et résidant au 239 rue Vanier, app.D., St-Jean,district d'Iberville, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec afin d'obtenir un décret changeant son nom à David Michael Darwin Robichaud.St-Jean, Québec, ce 28e jour de février 1975.Le procureur du requérant, 60796-19-2-o Gordon D.McKay, c.r.David Michael Darwin McDonald Notice is hereby given that David Michael Darwin McDonald, domiciled at 239 Vanier Street, Apartment D, St.Jean, in the District of Iberville, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to \"David Michael Darwin Robichaud\".St.Jean, Québec, February 28th, 1975.Gordon D.McKay, q.c, 60796-19-2-O Attorney for Applicant.Michel Gamache-Monier Avis est donné que Michel Gamache-Monier, célibataire domicilié et résidant au 18, Du Repos Ouest, Lac St-Charles, district de Québec, a déposé une requête auprès du ministre de la justice de la province de Québec pour obtenir un décret changeant son nom de Michel Gamache-Monier en celui de Michel Gamache.Québec, ce 18e jour du mois d'avril 1975.Le requérant, 60811-19-2-0 Michel Gamache-Monier.Michel Gamache-Monier Notice is hereby given that Michel Gamache-Monier, bachelor, domiciled and residing at 18, Du Repos Ouest, Lac St-Charles, district of Québec, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec for an order changing his name to that of Michel Gamache.Québec, 18th April 1975.Michel Gamache-Monier, 60811-19-2-o Petitioner. 3810 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, Ko, 19 Bernadel Decilus Thezier Avis est par les présentes donné que Bernadel Decilus Thezier, demeurant au 837, rue Perrier dans la ville de Brossard, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour changer légalement son nom pour celui de Vladimir Bernadel.Montréal, le 10 avril 1975.Le procureur du requérant, 60824-19-2-o Liliane Monier.Curatelle publique Succession Claude Lahaie Succession de Lahaie, Claude, en son vivant de 1080, rue Stc-.Iulie, Trois-Rivières, Québec, décédé le 15 juin 1974.Sous l'empire de la Loi de la Curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310.boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 60777-o Succession Patrick-Alexander Wilson Succession de Wilson, Patrick-Alexander, en son vivant de 11, boul.Dorchester, Montréal, P.Q., décédé le 26 décembre 1957.Sous l'empire de la Loi de la Curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310 boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 60779-o Succession Jean-Sylvio-Ernest Savard Succession de Savard, Jean-Sylvio-Ernest, en son vivant de 3495, rue de la Montagne, app.1006, Montréal, P.Q., décédé le 12 mars 1971.Sous l'empire de la Loi de la Curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310 boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 60780-o Bernadel Decilus Thezier Notice is hereby given that Bernadel Decilus Thezier residing at 837 Perrier Street, in the City of Brossard, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the adoption of an order changing his name to that of Vladimir Bernadel, the said name to serve for all legal purposes.Montreal, April 10, 1975.Liliane Monier, 60824-19-2-o Attorney for the applicant.Public Curatorship Estate of Claude Lahaie Estate of the late Lahaie, Claude, in his lifetime of 1080, rue Ste-Julie, Trois-Rivières, Québec, deceased June 15th, 1974.The undersigned hereby gives notice, in conformity with the Public Curatorship Act (S.Q.1971, ch.81), that he is ex-officio curator to such estate and that he will receive, at the following address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, Saint Lawrence Blvd.Montreal (Que.) H2N 1N6 60777-o Estate of Patrick-Alexander Wilson Estate of the late Wilson, Patrick-Alexander in his lifetime of 11, Dorchester Blvd., Montreal, deceased, December 26th, 1957.The undersigned hereby gives notice, in conformity with the Public Curatorship Act (S.Q.1971, ch.81), that he is ex-officio curator to such estate and that he will receive, at the following address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Quebec.9310, Saint Lawrence Blvd.Montreal (Que.) H2N 1N6 60779-o Estate of Jean-Sylvio-Ernest Savard Estate of the late Savard, Jean-Sylvio-Ernest, in his lifetime of 3495, De La Montagne Street, Apt.1006, Montreal, deceased March 12th, 1971.The undersigned hereby gives notice, in conformity with the Public Curatorship Act (S.Q.1971, ch.81), that he is ex-officio curator to such estate and that he will receive, at the following address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, Saint Lawrence Blvd., Montreal (Que.) H2N 1N6 60780-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3817 Succession John Porter Succession de Porter, John, en son vivant de 2115, rue Bedford, Montréal, Québec, décédé le 1er juillet 1969.Sous l'empire de la Loi de la Curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 60778-o Estate of John Porter Estate of the late Porter, John, in his lifetime of 2115, Bedford Street, Montreal, deceased July 1st, 1969.The undersigned hereby gives notice, in conformity with the Public Curatorship Act (S.Q.1971, ch.81), that he is ex-officio curator to such estate and that he will receive, at the following address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, Saint Lawrence Blvd.Montreal (Que.) H2N 1N6 60778-o Succession Clara Janes Oakes Succession de Oakes, Clara Janes, en son vivant de 1222, rue Meckay, Montréal, décédée le 28 décembre 1968.Sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6.60787-o Estate of Clara Janes Oakes Estate of the late Oakes, Clara Janes, in her lifetime of 1222 rue Meckay, Montreal, deceased december 28, 1968.The undersigned hereby gives notice, in conformity with the Pub'ic Curatorship Act (S.Q.1971, ch.81), that he is ex-officio curator to such estate and that he will receive, at the following address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, Saint Lawrence Blvd., Montreal (Que.) H2N 1N6 60787-o Demandes à la Législature Applications to Legislature Succession J.O.St-Pierre Avis est par les présentes donné que les héritiers de la succession de feu J.O.St-Pierre, de son vivant domicilié en la ville de Stanstead Plain, district de St-François, s'adresseront à l'Assemblée nationale du Québec, au cours de la présente session, en vue d'obtenir l'adoption d'une loi modifiant les dispositions du testament de feu J.O.St-Pierre, afin de permettre le partage immédiat de la succession, sous réserve d'une somme capitale suffisante pour garantir le paiement d'une rente annuelle viagère de $4,000 à Dame Thérèse St-Pierre Foumier.Montréal, ce 10 avril 1975.Les procureurs des requérants, 60618-16-4-o Lapointe et David.Estate of J.O.St-Pierre Notice is hereby given that the heirs to the estate of the late J.O.St-Pierre, in his lifetime domiciled at Stanstead Plain, District of St-François, will apply to the National Assembly of Québec, during its present session, in order to obtain the adoption of an act modifying the dispositions of the will of the late J.O.St-Pierre, so as to permit the immediate partition of the estate, subject to the setting up of a reserve of a capital amount sufficient to guarantee the payment of a lifetime annuity of $4,000 to Thérèse St-Pierre Fournier.Montreal, April 10, 1975.Lapointe et David, 60618-16-4-0 Attorneys for the petitioners.Ville de Longueuil Avis est par les présentes donné que la ville de Longueuil s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec à sa présente ou prochaine session ou la session suivante afin d'obtenir l'adoption d'un bill amendant sa charte pour les motifs suivants: 1.Autoriser la Ville à disposer d'immeubles acquis avec une restriction; City of Longueuil Public notice is hereby given that the City of Longueuil will apply to the Québec National Assembly, during its current or next session or the following one, for the passing of a Bill amending its charter, for the following purposes: 1.To permit the City to dispose of immoveables whose titles contain restrictions as to the future use it wishes to make of them; 3818 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10.1975, Vol.107, No.19 2.Autoriser la Ville à disposer de terrains acquis en surplus pour des fins municipales; 3.Autoriser la Ville à indemniser les membres du Conseil pour leur vacation à son service; 4.Rendre obligatoire la nomination annuelle de vérificateurs à date fixe; 5.Dispenser le greffier de la Ville de la lecture des règlements et autoriser leur adoption lors d'une assemblée ajournée; 6.Autoriser la Ville à limiter le nombre de commerces d'une même catégorie dans une zone donnée; 7.Éliminer le maximum fixé pour le tarif d'honoraires lors de l'émission de permis de construction; 8.Autoriser la Ville à faire faire la rénovation ou la démolition des habitations insalubres, vétustés ou endommagées sans avoir à se pourvoir en justice à cet effet; 9.Autoriser la Ville à requérir son approbation préalable à toute demande de subdivision, à conclure des conventions garantissant l'exécution des travaux municipaux et la rentabilité des projets de construction ; 10.Augmenter de 5% à 10% la superficie des terrains subdivisés pour fins de parcs ou de terrains de jeux; 11.Autoriser la Ville à percer des tunnels en profondeur sous toute propriété pour ses services d'aqueduc et d'égout sans avoir à payer l'indemnité; 12.Permettre la gradation des taux d'intérêt sur les arrérages de taxes; 13.Décréter que les frais de nettoyage de terrains sont assimilés à une taxe; 14.Sanctionner le droit de propriété lors d'une expropriation municipale, lorsque seul le montant de l'indemnité est contesté; 15.Permettre à la Ville d'examiner les effets endommagés lors d'une réclamation contre elle; 16.Autoriser la Ville à enchérir pour un montant supérieur aux taxes municipales lors de ventes à l'enchère ; 17.Reconnaître le droit de propriété de la Ville de certains terrains bordant les rives du St-Laurent dans son territoire; 18.Augmenter les montants minimum et maximum des amendes décrétées par les règlements municipaux; 19.Dispenser de l'approbation des propriétaires les emprunts touchant les travaux d'aqueduc, d'égout, de pavage et d'éclairage; 20.Indexer la pension des membres du Conseil; 21.Permettre à la Ville de détenir un permis de vente de boissons alcooliques; Et toute autre matière utile à la bonne administration des affaires de la Ville.Longueuil, 11 avril 1975.Paul Pellerin, 60622-16-4-o Avocat et procureur de la ville.2.To grant power to the City to dispose of the remaining parts of immoveables acquired for municipal purposes; 3.To authorize the City to pay an indemnity to the Council members for their attendances during their offices; 4.To compel the Council to appoint, yearly, at its first general sitting, two auditors; 5.To grant the City's clerk an exemption from reading any municipal By-laws; 6.To restrict in a zone the number of business of the same category; 7.To permit the City to establish its own tariff of fees payable for the issue of building permits; 8.To grant power to the City to order the demolition of any structures or building that may endanger life; 9.To authorize the City to require its approval in advance for all subdivision requests, to enter conventions to guarantee the execution of municipal works and the self-payment of construction projects; 10.To permit the City to raise from 5% to 10% the percentage of land required for parks and playgrounds purposes as a condition of the approval of a subdivision plan; 11.To exempt the City from paying any indemnity for the tunnelling under private properties at a depth of 25 feet or more; 12.To allow the use of graduated interest rates for tax arrears; 13.To declare that costs for the cleaning of lots are assimilated to taxes; 14.To sanction the right of ownership in a municipal expropriation when only the amount of indemnity is contested; 15.To allow the City to proceed to the examination of damaged goods in the case of claims against the City; 16.To authorize the City to bid at any sale of immoveable in its territory for an amount higher than the taxes; 17.To cede to the City rights of property on certain lots bordering the St.Lawrence River; 18.To raise the fines imposed by Municipal By-laws; 19.To exempt the City from seeking any approval but of the Minister of Municipal Affairs and the Municipal Commission to execute certain public works; 20.To adjust annually the benefits payable to the Council members under their pension plan; 21.To authorize the City to hold a permit to sell alcoholic beverages in any recreation centers and public places.And for any other Municipal purposes.Longueuil, April 11th, 1975.Paul Pellerin, 60622-16-4-o Attorney for the City of Longueuil. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1975.107' année, n' 19 3819 Corporation des Enseignants du Québec Avis est par les présentes donné que la « Corporation des Enseignants du Québec » s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec pour obtenir l'adoption d'une Loi aux fins suivantes: 1.Abrogation de la Loi constitutive de la Corporation des Enseignants du Québec (10 Georges VI, chap.87, et ses amendements) ; 2.Le transfert de tous les biens, droits et obligations de la « Corporation des Enseignants du Québec » à la « Centrale de l'Enseignement du Québec », formée en vertu de la Loi des syndicats professionnels (S.R.Q.1964, chap.146 et amendements); 3.Substitution de la « Centrale de l'Enseignement du Québec » à la « Corporation des Enseignants du Québec » dans toutes les lois, règlements, décrets, conventions collectives, ententes et procédures pendantes.Québec, ce 14 avril 1975.Les procureurs de la Corporation, («rondin, LeBel, Morin, Poudrier, 60649-16-4-o Isabel & Gaonon.Ville de Chibougamau Avis public est par les présentes donné que la ville de Chibougamau s'adressera à l'Assemblée nationale de Québec, à sa présente session ou à une session subséquente d'icelle, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte sur les matières suivantes: 1.Pour décréter que, dorénavant, les dispositions de l'article 2 de la Loi des villes minières (Statuts refondus, 1964, chapitre 194) ne s'appliqueront pas à la ville; 2.Pour décréter l'annexion au territoire actuel de la ville d'un territoire contigu à ses limites, tel territoire formant actuellement partie de la municipalité de la Baie James de manière à étendre de cinquante (50) milles en profondeur les limites actuelles de la ville, distraction faite du territoire de la ville de Chapais; 3.Pour décréter que, sous réserve de l'article 41 de la Loi du développement de la région de la Baie James (chapitre 34 des lois de 1971), les dispositions du paragraphe c de l'article 29 de la Loi des mines (chapitre 34 des lois de 1965, tel qu'amendé) ne s'appliqueront pas au territoire annexé par la ville sauf quant à la partie réservée par résolution du conseil pour le développement de l'agglomération urbaine, et pour toutes autres fins.Québec, ce 16 avril 1975.Le procureur de la ville, 60654-17-4-o Pierre Cantin.Ville de Châteauguay-Centre Ville de Châteauguay Avis conjoint Prenez avis que la ville de Châteauguay-Centre et la ville de Châteauguay, dans le comté de Châteauguay, s'adresseront à la présente session, au Comité des bills privés de l'Assemblée Nationale du Québec, afin de faire adopter une loi aux fins suivantes: Corporation des Enseignants du Québec Notice is hereby given that the \"Corporation des Enseignants du Québec\" will apply to the National Assembly of Québec to request the adoption of a Bill for the following puiposes: 1.The repeal of the Act incorporating the \"Corporation des Enseignants du Québec\" (10 George VI, Chapter 87 and amendments) ; 2.The transfer of all property, rights and obligations of the \"Corporation des Enseignants du Québec\" to the \"Centrale de l'Enseignement du Québec\", constituted pursuant to the Professional Syndicates Act (R.S.Q.1964, Chapter 146 and amendments); 3.The substitution of the name \"Centrale de l'Enseignement du Québec\" for \"Corporation des Enseignants du Québec\" in all acts, bylaws, orders, collective and other agreements and pending proceedings.Québec, April 14, 1975.Grondin, LeBel, Morin, Poudrier, Isabel & Gagnon, 60649-16-4 Attorneys for the Corporation.Town of Chibougamau Public notice is hereby given that the Town of Chibougamau will apply to the National Assembly of Québec, at its present session or at a future session thereof, for the adoption of an act amending its charter, for the following purposes: 1.To order that, in the future, the provisions of section 2 of the Mining Towns Act (Revised Statutes, 1964, chapter 194) shall no longer apply to the Town; 2.To order the annexation to the present territory of the Town of a territory contiguous to or adjoining its limits, such territory presently forming part of the territory of the James Bay Municipality with the result that the present limits of the Town shall be extended by fifty (50) miles in depth, excepting however the territory of the Town of Chapais; 3.To order that, under reserve of section 41 of the James Bay Region Development Act (chapter 34 of the laws of 1971), the provisions of paragraph c of section 29 of the Mining Act (chapter 34 of the laws of 1965, as amended), shall not apply to the territory annexed by the Town excepting however that part reserved by the resolution of the council for urban development, and for any other purpose.Québec, this 16th day of April, 1975.Pierre Cantin, 60654-17-4-o Solicitor for the Town.Town of Châteauguay-Centre Town of Châteauguay Joint notice Notice is hereby given that the Towns of Châteauguay and Châteauguay-Centre, in the county of Châteauguay, shall apply to the Private Bill Committee of the National Assembly at the present Session for the adoption of a law for the following purposes: 3820 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 1.Fusionnant les deux municipalités actuelles en une nouvelle municipalité connue sous le nom de « Châteauguay ».2.Le territoire de cette ville comprendra le territoire actuel de la ville de Châteauguay-Centre et celui de la ville de Châteauguay.3.Cette ville sera administrée par un maire et six conseillers, et sera divisée en six quartiers pour fins électorales.4.La première élection générale du maire et des conseillers aura lieu le premier dimanche de novembre 1975.5.Une liste électorale de la nouvelle ville sera confectionnée avant l'élection, avec les modalités prévues.6.Un Comité consultatif temporaire sera créé pour voir à l'intégration des services municipaux, l'aménagement des plans directeurs en un seul et pour fins d'urbanisme.7.Tout déficit de chacune des deux villes pourra être consolidé par un règlement et ce règlement n'affectera que les immeubles situés dans le territoire de la ville d'où origine ce déficit et pour toutes autres fins.Ce 2 avril 1975.Laurier Legault, Greffier de la ville de Châleauguay-Cenlre.Jacques Rivard, Greffier de la ville de Châteauguay.Armand Poupart Jr., 60823-19-4-o Procureur des pétitionnaires.Communauté urbaine de Montréal Avis est par les présentes donné que la Communauté urbaine de Montréal ayant son siège social dans la ville de Montréal, s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec, à sa présente ou à sa prochaine session, afin d'obtenir l'adoption d'une loi pour: 1.modifier le mode d'expédition de l'ordre du jour des assemblées de la Communauté et de l'avis de convocation de ces assemblées; 2.autoriser certains fonctionnaires à recevoir la prestation des serments; 3.prévoir certaines dispositions pour la protection de la flore sur le territoire de la Communauté; 4.préciser la juridiction de la Communauté en matière d'élimination de la pollution de l'air; 5.augmenter le taux de la taxe perçue par les municipalités sur l'excédent de l'évaluation des immeubles au-delà de $100,000, étendre et préciser le délai de remboursement des taxes entre les municipalités et la Communauté ainsi que le mode de répartition des dépenses de la Communauté; 6.augmenter le fonds de roulement de la Communauté et modifier certaines de ses dispositions; 7.autoriser la Communauté à répartir certaines subventions gouvernementales; 8.avec l'approbation du ministre des transports du Québec, autoriser la Communauté à fournir à autrui et contre rémunération, des services, de l'équipement et des matériaux en matière de transport; 1.Amalgamating the two municipalities in one, known as \"Châteauguay\".2.The territory of this Town shall include the actual territories of Châteauguay and Châteauguay-Centre.3.This Town shall be administered by a Mayor and six Aldermen, and shall be devided into six Wards for electoral purposes.4.The first general election for mayor and aldermen shall take place the first Sunday of November 1975.5.The electoral list shall to be made before the election with the appropriate legal requirements.6.A temporary Committee shall be created for the integration of municipal services, master plan town-planning purposes.7.Any deficit from the municipalities could be consolidated by a special by-law affecting only the immovables in the territory where the deficit is created.This 2nd day of April 1975.Laurier Legault, Clerk, Town of Châteauguay-Centre.Jacques Rivard, Clerk, Town of Châteauguay.Armand Poupart, Jr., 60823-19-4-o Attorney for Petitioners.Montreal Urban Community Notice is hereby given that the Montreal Urban Community, having its head office in the City of Montreal, will apply to the National Assembly of Québec, at its present or next session, to obtain the adoption of an act so as to : 1.modify the mode of service of notices and agenda of meetings of the Council of the Community; 2.authorize certain officials to administer oaths; 3.enact certain provisions for the protection of flora on the territory of the Community; 4.explicit the jurisdiction of the Community concerning elimination of air pollution; 5.increase the tax rate collected by the municipalities, on the excess over $100,000 of the valuation of properties, and specify the delay of reimbursement of taxes as between municipalities and the Community together with the mode of apportionment of the Community's expenses; 6.increase the Community's working fund and modify certain of its provisions; 7.authorize the Community to apportion certain governmental subsidies; 8.with the approval of the Minister of transport of Québec, authorize the Community to provide third parties, against remuneration, with services, equipment and materials related to transportation; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3821 9.préciser certaines dispositions de nature administrative; et à diverses autres fins.Montréal, ce 18e jour d'avril 1975.Les procureurs de la Communauté urbaine de Montréal, Beaupré, Trudeau, 60795-19-4-o Sylvestre & Taillefer.Avis divers INSTITUT ARMAND-FRAPPIER Avis est par la présente donné que le conseil d'administration de l'Institut de Microbiologie et d'Hygiène de Montréal a résolu que, à partir du 1er juin 1975, l'Institut portera le nom de INSTITUT ARMAND-FRAPPIER, en vertu de l'arrêté en conseil no 2227-72 du 26 juillet 1972.Le secrétaire général, 60793-o Jeannine Beaudoin.Conseil no 6636 - Giffard des Chevaliers de Colomb de Giffard Avis est donné que le « Conseil no 6636 Giffard des Chevaliers de Colomb de Giffard », 3365, avenue Royale, Giffard, possède son siège social à l'adresse susmentionnée et qu'il se prévaut des dispositions de la Loi concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec (1-2 Elizabeth II, chap.134) à partir du 25 février 1975.Giffard, 25 février 1975.Le grand chevalier, André Labbé.Le secrétaire-archiviste, Marcel Robitaille.60794-o 1362-6288 EXPLO-ZINC INC.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières, il a accordé des lettres patentes en date du 14e jour de mars 1975, constituant en corporation: Jacques R.Ranoux, administrateur, 3495, de la Montagne, Montréal, Georges Girard, administrateur, 62, Mfin ouest, Magog, Jean-Pierre Sutto, avocat, 135, Deguire, Saint-Laurent, Colin A.Gravenor, avocat, 428, avenue Wood, Westmount et Jean Biron, avocat, 3060, chemin St-Sulpice, Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais, sous le nom de « ËXPLO-ZINC INC.», avec un capital divisé en 5,000,000 d'actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est situé au numéro 2100, Drummond, suite 770, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.60757-o 1362-3699 9.modify and clarify certain administrative provisions; and for various other purposes.Montreal, this 18th day of April, 1975.Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, Attorneys for Montreal 60795-19-4-o Urban Community.Miscellaneous Notices INSTITUT ARMAND-FRAPPIER Notice is hereby given that the Board of Administrators of the Institut de Microbiologie et d'Hygiène de Montreal has decided that, on and after June 1, 1975, the Institute will be bearing the name of INSTITUT ARMAND-FRAPPIER under the Order in Council No.2227-72 issued on July 26, 1972.Jeannine Beaudoin, 60793-o Secretary-general.Council No.6636 - Giffard of the Knights of Columbus of Giffard Notice is given that \"Council No.6636 Giffard of the Knights of Columbus of Giffard\", 3365 Avenue Royale, Giffard, has its head office at the aforesaid address and that it avails itself of the provisions of the Act respecting the Knights of Columbus of the Province of Québec (1-2 Elizabeth II, chap.134) from 25 February 1975.Giffard, 25 February, 1975.André Labbé, Grand Knight.Marcel Robitaille, Registrar.60794-o 1362-6288 EXPLO-ZINC INC.Notice is given that under the provisions of the Mining Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of March, 1975, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques R.Ranoux, executive, 3495 Mountain, Montreal, Georges Girard, executive, 62 Main West, Magog, Jean-Pierre Sutto, lawyer, 135 Deguire, Saint-Laurent, Colin A.Gravenor, lawyer, 428 Wood Avenue, Westmount and Jean Biron, lawyer, 3060 Saint-Sulpice Road, Montreal, for the following purposes: To explore or prospect for mines and minerals, under the name of \"EXPLO-ZINC INC.\", with a capital stock divided into 5,000,000 common shares without par value.The head office of the Company is located at 2100 Drummond, Suite 770, Montreal, Judicial District of Montreal.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.60757 1362-3699 :>,vj2 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 FONDATION ROSALIE JETTE Avis est donné qu'en vertu de l'article 21 de la Loi concernant Les Soeurs de Miséricorde de Montréal, chapitre 125 des lois de 1963 Sess.1, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province île Québec, des lettres patentes, en date du 23 janvier 1975, constituant en corporation « FONDATION ROSALIE JETTE ».Le siège social de la corporation ci-haut mentionnée est situé à Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.60757-o 1361-4292 FONDATION ROSALIE JETTE Notice is given that pursuant to section 21 of the Act respecting the Misericordia Sisters of Montreal, Chapter 125 of the Statutes of 1963, first session, the Lieutenant-Governor of the Province of Québec has issued letters patent, dated January 23, 1975, incorporating \"FONDATION ROSALIE JETTE\".The head office of the aforesaid Corporation is located in Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60757 1361-4292 Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions CAISSE POPULAIRE SAINT-ARSENE DE MONTREAL (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 29 janvier 1975 par la « CAISSE POPULAIRE SAINT-ARSENE», changeant son nom en celui de « CAISSE POPULAIRE SAINT-ARSENE DE MONTREAL».Québec, le 29 avril 1975.Le sous-ministre des institutions fiyiancières, compagnies et coopératives, 60820-o Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DE STE-CROIX (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 26 février 1975 par « Stc-Croix », changeant son nom en celui de « La Caisse populaire de Ste-Croix ».Québec, le 29 avril 1975.Le sous-ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, 60821-o Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PATRICE DE MAGOC (Loi des caisses d'épargne el de crédit) Avis est donné que le ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 9 décembre 1974 par « La Caisse Populaire de St-Patricc de Magog », modifiant son territoire qui était « la paroisse St-Patricc de Magog » en celui de la « Cité de Magog et Canton de Magog ».Québec, le 29 avril 1975.Le sous-minislre des Institutions financières, compagnies et coopératives, 60822-o Albert Jessop.CAISSE POPULAIRE SAINT-ARSENE DE MONTREAL (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on January 29, 1975 by the \"CAISSE POPULAIRE SAINT-ARSENE\", changing its name to that of \"CAISSE POPULAIRE SAINT-ARSENE DE MONTREAL\".Québec, April 29, 1975.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60820 Companies and Cooperatives.LA CAISSE POPULAIRE DE STE-CROIX (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, has approved the bylaw adopted on February 26, 1975 by \"Ste-Croix\", changing its name to that of \"La Caisse populaire de Stc-Croix\".Québec, April 29, 1975.Albert Jessop, Deputy Minister of Fviancial Institutions, 60821 Companies and Cooperatives.LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PATRICE DE MAGOG (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on December 9, 1974 by \"La Caisse Populaire de St-Patricc de Magog\", modifying its territory, which was \"the Parish of St-Patricc, in Magog\", to that of the City of Magog and the Township of Magog\".Québec, April 29, 1975.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60822 Companies and Cooperatives. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n\" 19 3n2:ï LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ST-JEAN VIANNEY (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a approuvé le règlement adopté le 19 novembre 1974 par « LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ST-JEAN VIANNEY » modifiant son territoire qui était « la paroisse de Saint-Jean-Vianney de Montréal » en celui des « villes de Montréal et d'Anjou et des cités de Montréal-Nord et de Saint-Léonard ».Québec, le 29 avril 1975.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 60819-o Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ST-JEAN VIANNEY (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on November 19, 1974 by \"LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ST-JEAN VIANNEY\", changing its territory, which was the \"Parish of Saint-Jean-Vianney, in Montreal\", to that of \"the Cities of Montreal, Montreal-North and Saint-Léonard, and the Town of Anjou\".Québec, April 29, 1975.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60819 Companies and Cooperatives.Services de santé et services sociaux \u2014 Loi sur Health Services and Social Services \u2014 Act on CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPESIE ET DES ILES-DE-LA-MADELEINE Le ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 47, 82 et 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour d'avril 1975, convertissant « SERVICE SOCIAL DE GASPE », constituée le 13 juillet 1967 en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, en un établissement public sous le nom de « CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPESIE ET DES ILES-DE-LA-MADELEINE ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE DE SERVICE SOCIAUX ».Le siège social de l'établissement est à Gaspé, district judiciaire de Gaspé.Le ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.60757-o 1362-4515 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES LONGUEUIL-EST Le ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement public sous le nom «CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES LONGUEUIL-EST ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ».Le siège social de l'établissement est à Longueuil, district judiciaire de Montréal.Le ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives.William Tetley.60757-o 1362-0455 CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPESIE ET DES ILES-DE-LA-MADELEINE The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that under sections 47, 82 and 83 of the Act respecting health services and social services.Chapter 48 of the Statutes of 1971, he has issued letters patent bearing date the 11th day of April, 1975, converting \"SERVICE SOCIAL DE GASPE\", incorporated on July 13, 1967 under Part III of the Companies Act, into a public establishment under the name of \"CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPESIE ET DES ILES-DE-LA-MADELEINE\".Said public establishment shall be classified as a \"SOCIAL SERVICE CENTRE';.The head office of this establishment is located in Gaspé, Judicial District of Gaspé.William Tetlry, Mi/iister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60757 1362-4515 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES LONGUEUIL-EST The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that under sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services, Chapter 48 of the Statutes of 1971, he has issued letters patent incorporating a public establishment under the name of \"CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES LONGUEUIL-EST\".Said public establishment shall be classified as a \"LOCAL COMMUNITY SERVICE CENTRE\".The head office of this establishment is located in Longueuil, Judicial District of Montreal.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60757 1362-0455 3824 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Ministère de l'Éducation Department of Education Municipalité scolaire des Cèdres Avis est par la présente donné qu'un certain territoire a été détaché de la municipalité scolaire du Lac-Mégantic et annexé, pour les catholiques, au sens de l'article 49 de la Loi de l'instruction publique, à la municipalité scolaire des Cèdres.Et ce, en vertu de l'arrêté en conseil numéro 1587-75 en date du 23 avril 1975, dont le texte suit: Concernant l'annexion d'un certain territoire, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire des Cèdres.Que les lots 11 à 1S inclusivement du rang VII du cadastre officiel du canton d'Aylmer, dans le comté de Frontenac, soient détachés de la municipalité du Lac-Mégantic et annexés, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire des Cèdres, et ce, conformément aux articles 46 et 49 de la Loi de l'instruction publique, Statuts refondus, 1964, chapitre 235.Le ministre de l'Éducation, François Cloutier.Ce changement prendra effet le 1er juin pour fins d'élection et le premier juillet 1975, pour toutes autres fins.60835-o Municipalité scolaire du Lac-Mégantic Avis est par la présente donné qu'un certain territoire a été détaché de la municipalité scolaire des Cèdres et annexé, pour les catholiques au sens de l'article 49 de la Loi de l'instruction publique, à la municipalité scolaire du Lac-Mégantic.Et ce, en vertu de l'arrêté en conseil numéro 1588-75 en date du 23 avril 1975, dont voici le texte: Concernant l'annexion d'un territoire, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire du Lac-Mégantic.Que les lots 20 à 28 inclusivement du rang VIII du cadastre officiel du canton Lambton, dans le comté de Frontenac, soient détachés de la municipalité scolaire des Cèdres et annexés, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire du Lac-Mégantic.et ce, conformément aux articles 46 et 49 de la Loi de l'instruction publique.Statuts refondus, 1964, chapitre 235.Le ministre de l'Education, François Cloutier.Ce changement prendra effet le premier juin pour fins d'élection et le premier juillet 1975, pour toutes autre fins.60835-o Des Cèdres School Municipality Notice is hereby given that a certain territory has been detached from the Lac-Mégantic School Municipality and annexed, for Roman Catholics only, within the meaning of section 49 of the Education Act, to the Des Cèdres School Municipality.The foregoing, pursuant to Order in Council numbered 1587-75, dated April 23, 1975, which reads as follows: Respecting the annexation of a certain territory, for Roman Catholics only, to the Des Cèdres School Municipality.That lots 11 to 18 inclusive, in Range VII, on the official cadastre for the Township of Aylmer, in the County of Frontenac, be detached from the Lac-Mégantic School Municipality and annexed, for Roman Catholics only, to the Des Cèdres School Municipality, the foregoing, in conformity with sections 46 and 49 of the Education Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 235.François Cloutier, Minister of Education.The aforesaid modification shall come into force on the first of June for election purposes and on the first of Julv, 1975, for all other purposes.60835 Lac-Mégantic School Municipality Notice is hereby given that a certain territory has been detached from the Des Cèdres School Municipality and annexed, for Roman Catholics only, within the meaning of section 49 of the Education Act, to the Lac-Mégantic School Municipality.The foregoing, pursuant to Order in Council numbered 1588-75, dated April 23, 1975, which reads as follows: Respecting the annexation of a territory, for Roman Catholics only, to the Lac-Mégantic School Municipality.That lots 20 to 28 inclusive, in Range VIII on the official cadastre for the Township of Lambton, in the County of Frontenac, be detached from the Des Cèdres School Municipality and annexed, for Roman Catholics only, to the Lac-Mégantic School Municipality, the foregoing, in conformity with sections 46 and 49 of the Education Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 235.François Cloutier, Minister of Education.The aforesaid modification shall come into force on the first of June for election purposes and on the first of July, 1975, for all other purposes.60835 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1915, 10T année, n° 19 3825 Soumissions \u2014 Demandes de Cité de Charlesbourg Comté de Charlesbourg Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription «Soumissions pour obligations» seront reçues par le soussigné Rosaire Godbout, greffier.Hôtel de ville, 7575, boulevard Henri-Bourassa, Charlesbourg, comté de Charlesbourg, P.O.jusqu'à 6.00 heures p.m., lundi, le 26 mai 1975, pour l'achat de SI,668.500 d'obligations de la cité de Charlesbourg, comté de Charlesbourg, datées du 15 juin 1975 et remboursables en série du 15 juin 1976 au 15 juin 1995 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement les 15 décembre et 15 juin de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juin 1975.Tableau d'amortissement \u2014 $1,668.500 \u2014 20 ans Date Capital 15 06 1976 .S 28.500 15 06 1977 .31,000 15 06 1978 .33,000 15 06 1979 .36.000 15 06 1980 .39.000 15 06 1981 .42.000 15 06 1982 .47,000 15 06 1983 .51,000 15 06 1984 .54.000 15 06 1985 .59.000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série I à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec un montant de $616.000 (comprenant les amortissements du 15 juin 1986 au 15 juin 2006 incl.) reporté au 15 juin 1980 et le solde de $632.000 (comprenant les amortissements du 15 juin 2007 au 15 juin 2015 incl.) reporté au 15 juin 1985.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $96.000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des Tenders \u2014 Requests for Cily of Charlesbourg County of Charlesbourg Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Rosaire Godbout, City Clerk, at Ihe City Hall.7575 Henri-Bourassa Boulevard.Charlesbourg, County of Charlesbourg.P.Q., until 6:00 o'clock p.m., on Monday May 26.1975, for the purchase of a bond issue of $1.668.500 for the City of Charlesbourg, County of Charlesbourg, dated June 15.1975 and redeemable serially from June 15.1976 lo June 15.1995 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%.nor more than 9'/;%, payable semiannually on December 15lh and June 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rale must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from June 15, 1975.Redemption table \u2014 SI .668.500 \u2014 20 years \tDate\t\tCapital 15\t06\t1986 .\t.$ 20.000 IS\t06\t1987 .\t.22.000 15\t06\t1988 .\t.25.000 15\t06\t1989 .\t.26.000 15\t06\t1990 .\t.29.000 IS\t06\t1991 .\t.26.000 IS\t06\t1992 .\t.28,000 15\t06\t1993 .\t.31.000 15\t06\t1994 .\t.33.000 IS\t06\t1995 .\t.1.008,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.I to 10-year serial bonds with (he balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.I to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and Ihe other part as 20-year fixed-term bonds.5.I to 10-year serial bonds in the amount of $616,000 (including redemptions of June 15, 1986 and June 15,2006 inclusive) carried forward lo June 15, 1980 and the balance of $632,000 (including redemptions of June 15.2007 and June 15, 2015 inclusive) carried forward to June 15, 1985.However, in the case of (he last method of payment, the 20-year fixed-lerm bonds should not be for an amount less than $96,000 and if greater lhan the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annu- 3826 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10.1975.Vol.107, No.19 amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 juin 2015 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 juin 1995 au montant de $1,008.000 comprend un solde de $972,000 renouvelable pour une période additionnelle de 20 ans.et échéant comme suit: Date Capital 15 06 1996 .$ 20.000 15 06 1997 .22.000 15 06 1998 .23.000 15 06 1999 .25.000 15 06 2000 .28,000 15 06 2001.30,000 15 06 2002 .32.000 15 06 2003 .35.000 15 06 2004 .38,000 15 06 2005 .42,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $ 1.008.000 et seul cet excédent sera rechetable par anticipation au pair le 15 juin de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La cité de Charlesbourg s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juin 1975 sans une autorisa-lion écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 330 \u2014 $31.000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 331 \u2014 $19.000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 335 \u2014 $12,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 336 \u2014 $7.000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 337 \u2014 $14,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 367 \u2014 $14,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 369 \u2014 $29,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 889 \u2014 $619,000 \u2014 aqueduc el égouts; 896 \u2014 $66.000 \u2014 achat d'un camion; 926 \u2014 $29,600 \u2014 achat d'un camion incendie; 958 \u2014 $157,600 \u2014 voirie; 965 \u2014 $536,300 \u2014 aqueduc el égouts; 970 \u2014 $13,400 \u2014 voirie; 983 \u2014 $12,600 \u2014 voirie.992 \u2014 $39.000 \u2014 aqueduc et égouts; 995 \u2014 $18.100 \u2014 aqueduc et égouts; 1002 \u2014 $37,600 \u2014 al redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of June 15.2015 of the renewal part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of June 15, 1995 in the amount of $ 1,008,000 includes a balance of $972,000 renewable for an additional 20-year period, maturing as follows: Date Capital 15 06 2006 .$ 45,000 15 06 2007 .49,000 15 06 2008 .53,000 15 06 2009 .58,000 15 06 2010 .64,000 15 06 2011.69,000 15 06 2012 .75,000 15 06 2013 .80,000 15 06 2014 .88,000 15 06 2015 .96.000 The succesful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $1,008,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on June 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to \\% of the amount of the loan.The City of Charlesbourg agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after June 15, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 330 \u2014 $31,000 \u2014 loan renewal; 331 \u2014 $19,000 \u2014 loan renewal; 335 \u2014 $12,000 \u2014 loan renewal; 336 \u2014 $7,000 \u2014 loan renewal; 337 \u2014 $14,500 \u2014 loan renewal; 367 \u2014 $14.000 \u2014 loan renewal; 369 \u2014 $29,000 \u2014 loan renewal; 889 \u2014 $619,000 \u2014 waterworks and sewers; 896 \u2014 $66,000 \u2014 purchase of a truck; 926 \u2014 $29,600 \u2014 purchase of a fire truck; 958 \u2014 $157,600 \u2014 roads; 965 \u2014 $536,300 \u2014 waterworks and sewers; 970 \u2014 $13,400 \u2014 roads; 983 \u2014 $12,600 \u2014 roads; 992 \u2014 $39,000 \u2014 waterworks and sewers; 995 \u2014 $18,100 \u2014 waterworks and sewers, 1002 \u2014 $37.600 \u2014 recreational and community services; 1008 \u2014 $12,800 \u2014 purchase of machinery. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n' 19 3827 services récréatifs et communautaires; 1008 \u2014 $12,800 \u2014 achat de machinerie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 6.00 heures p.m., lundi, le 26 mai 1975, Hôtel de ville, 7575.boulevard Henri-Bourassa, cité de Charlesbourg.comté de Charlesbourg, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Charlesbourg (Comté de Charlesbourg), ce 1er mai 1975.Le greffier, Rosaire Godbout.Hôtel de ville.7575.boulevard Henri-Bourassa, Charlesbourg (Charlesbourg), Québec.Téléphone: 623-9816, code 418.6078 l-o La commission scolaire Des Chenaux Siège social: 30, rue Sl-Charles, Ste-Geneviève-de-Batiscan, (Champlain), P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription «Soumissions pour obligations» seront reçues par le soussigné André Adam, directeur-général.Centre administratif, 30 rue St-Charles, Ste-Geneviève-de-Batiscan, comté de Champlain, P.O., jusqu'à 8.00 heures du soir, mardi, le 27 mai 1975, pour l'achat de $179,000 d'obligations pour la commission scolaire Des Chenaux, datées du 15 juin 1975 et remboursables en série du 15 juin 1976 au 15 juin 1985 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9'/;%, payable semi-annuellement les 15 décembre et 15 juin de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juin 1975.Tableau d'amortissement \u2014 $179,000 \u2014 10 ans Date Capital 15 06 1976 .$12.000 15 06 1977 .13,000 15 06 1978 .14,000 15 06 1979 .15.000 15 06 1980 .16,000 La commission scolaire Des Chenaux, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des Finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held at 6:00 o'clock p.m.on Monday, May 26, 1975.at the City Hall.7575 Henri-Bourassa.Boulevard, City of Charlesbourg, County of Charlesbourg, The Council does not bind itself to accept Ihe highest or any of the tenders.Charlesbourg (County of Charlesbourg).May 1.1975.Rosaire Godbout, City Clerk.City Hall, 7575 Henri-Bourassa Boulevard.Charlesbourg (Charlesbourg).Québec.Telephone: 623-9816, code 418.60781 The Des Chenaux School Board Head Office: 30 St-Charles Street.Ste-Geneviève-de-Batiscan, County of Champlain, P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, André Adam, Director General, that the Administration Centre, 30 Saint-Charles Street, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, County of Champlain, P.Q.until 8:00 p.m., on Tuesday, May 27.1975, for the purchase of a bond issue of $179,000 for the Des Chenaux School Board, dated June 15, 1975 and redeemable serially from June 15, 1976 to June 15, 1985 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more 9'/:%, payable semiannually on December 15th and June 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from June 15, 1975.Redemption table \u2014 $179.000 \u2014 10 years Date Capital 15 06 1981.$18.000 15 06 1982 .20,000 15 06 1983 .22.000 15 06 1984 .23,000 15 06 1985 .26.000 The Des Chenaux School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to Ihe said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required. 3828 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 On est prié de noler que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront par rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à \\% du montant de l'emprunt.La commission scolaire Des Chenaux s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juin 1975, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu de la résolution datée du 28 janvier 1975 \u2014 $179.000 \u2014 dépenses d'immobilisations.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 27 mai 1975, à 8.00 heures du soir, Centre administratif, 30 rue St-Charles, Ste-Geneviève-de-Batiscan, comté de Champlain, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ste-Geneviève-de-Batiscan, (comté de Champlain), ce 5 mai 1975.Le directeur général, André Adam.Ste-Geneviève-de-Batiscan, Comté de Champlain, P.Q.Téléphone: 362-2721, code 418 60833-o Ville de Varennes Comté de Verchères Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription «Soumissions pour obligations» seront reçues par le soussigné Jean-Guy Champoux, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, 175, rue Ste-Anne, ville de Varennes, comté de Verchères, P.Q., jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, le 26 mai 1975 pour l'achat de $1,452,000 d'obligations de la ville de Varennes, comté de Verchères, datées du 15 juin 1975 et remboursables en série du 15 juin 1976 au 15 juin 1995 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9'l2%, payable semi-annuellement les 15 juin et 15 décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juin 1975.It is to be noted that the tenders are called for bonds redeemable as per the above table only, and that offers which might be made for short-term bonds will not be considered.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Des Chenaux School Board agrees not lo bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after June 15, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the resolution dated January 28, 1975 \u2014 $ 179,000 \u2014 capital expenditure.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Tuesday, May 27, 1975, at 8:00 o'clock p.m.at the Administration Centre, 30 Saint-Charles Street, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, County of Champlain, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Sainle-Geneviève-de-Batiscan, (County of Champlain), May 5, 1975.Andre Adam, Director-General.Administration Centre, 30 Saint-Charles Street, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, County of Champlain, P.Q.Telephone: 362-2721, code 418.60833 City of Varennes County of Verchères Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Jean-Guy Champoux, Secretary-Treasurer, at the City Hall, 175 Sainte-Anne Street, City of Varennes, County of Verchères, P.Q., until 8:00 p.m.on Monday, May 26, 1975, for the purchase of a bond issue of $ 1,452.000 for the City of Varennes, County of Verchères, dated June 15, 1975 and redeemable serially from June 15, 1976 to June 15, 1995 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9'/:%, payable semiannually on June 15th and December 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from June 15, 1975. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 .3829 Tableau d'amortissement \u2014 $1.452.000 \u2014 20 ans Date Capital 15 06 1976 .$ 30.000 15 06 1977 .34,000 15 06 1978 .36.000 15 06 1979 .39,000 15 06 1980 .45,000 15 06 1981.28,000 15 06 1982 .30,000 15 06 1983 .33.000 15 06 1984 .36.000 15 06 1985 .39.000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec un montant de $578,000 (comprenant les amortissements du 15 juin 1986 au 15 juin 1995 incl.) reporté au 15 juin 1980 et le solde de $524,000 (comprenant les amortissements du 15 juin 1996 au 15 juin 2005 incl.) reporté au 15 juin 1985.Toutefois, pour celle dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $76.000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 juin 2005 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 juin 1995 au montant de $600,000 comprend un solde de $524.000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans.et échéant comme suit: Date Capital 15 06 1996 .$ 34.000 15 06 1997 .37.000 15 06 1998 .40.000 15 06 1999 .44.000 15 06 2000 .48.000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Redemption table \u2014 $1,452.000 \u2014 20 years Date Capital 15 06 1986 .$ 43.000 15 06 1987 .48.000 15 06 1988 .51.000 15 06 1989 .56.000 15 06 1990 .59.000 15 06 1991.53.000 15 06 1992 .58.000 15 06 1993 .64,000 15 06 1994 .70,000 15 06 1995 .600.000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to Ihe tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.5.1 to 10-year serial bonds in the amount of $578,000 (comprising the redemptions of June 15, 1986 to June 15, 1995 incl.) carried forward to June 15.1980 and the balance of $524,000 (comprising the redemptions of June 15.1996 to June 15.2001 incl.) carried forward lo June 15, 1985.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $76,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of June 15.2002 of Ihe renewable part hereinafter mentioned.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of June 15.1995 in the amount of $600.000 includes a balance of $524.000 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Date Capital 15 06 2001.$ 53.000 15 06 2002 .58,000 15 06 2003 .64.000 15 06 2004 .70.000 15 06 2005 .76.000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, al the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque. :ts;io QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1976, Vol.107, No.19 Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $600,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 juin de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Varennes s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juin 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 414 \u2014 $199,500 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 54 \u2014 $9,500 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 21 \u2014 $134,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 43 \u2014 $76,500 \u2014 voirie; 45 \u2014 $900,000 \u2014 construction d'un aréna; 47 \u2014 $29,000 \u2014 aqueduc, égouts; 53 \u2014 $3,500 \u2014 aqueduc, égouts; 59 \u2014 $100,000 \u2014 fonds de roulement.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue, lundi, le 26 mai 1975, à 8.00 heures du soir, Hôtel de ville, 175, rue Ste-Annc, ville de Varennes, comté de Verchères, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Varennes (Comté de Verchères), ce 1er mai 1975.Le secrétaire-trésorier, Jean-Guy Champoux.Hôtel de ville.175.rue St-Anne.Ville de Varennes (Comté de Verchères), P.O.Téléphone: 652-2683 652-9888, code 514.6083 l-o Commission scolaire régionale de l'Oulaouais Siège social: 225, nie St-Rédempleur Hull, (Hull).P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription «Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Jean Larsi-mont, directeur général, jusqu'à 4.30 heures de l'après-midi.Centre administratif, 225, rue St-Rédempteur, Hull, (Hull), P.O.et par après jusqu'à 8.00 heures du soir.École Gamelin, 250.boul.Gamelin, Hull, (Hull) P.Q.lundi, le 26 mai 1975 pour l'achat de $2,060,000 d'obligations de la commission scolaire régionale de l'Oulaouais, datées du 15 juin 1975 et remboursables en série du 15 juin 1976 au 15 juin 1995 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%.ni supérieur à 9'/>%, payable semi-annucllemenl les 15 décembre et 15 juin de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Capital and interest are payable at all branches m Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $600.000 and the daid surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on June 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to \\% of the amount of the loan.The City of Varennes agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after June 15.1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 414 \u2014 $199,500 \u2014 waterworks, sewers, roads; 54 \u2014 $9,500 \u2014 waterworks, sewers, roads; 21 \u2014 $134,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; 43 \u2014 $76,500 \u2014 roads; 45 \u2014 $900,000 \u2014 construction of an arena; 47 \u2014 $29,000 \u2014 waterworks, sewers; 53 \u2014 $3,500 \u2014 waterworks, sewers; 59 \u2014 $100.000 \u2014 operating capital.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held on Monday, May 26, 1975, at 8:00 p.m., at the City Hall, 175 Sainte-Anne Street, City of Varennes, County of Verchères, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Varennes (County of Verchères), May 1, 1975.Jean-Guy Champoux, Secretary-Treasurer.City Hall, 175 Sainte-Anne Street, City of Varennes (County of Verchères), P.O.Telephone: 652-2683 652-9888, code 514.60831 The Outaouais Regional School Board Head Office: 225 St-Rédempteur Street, Hull (Hull), P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned.Jean Larsimont.Director-General, until 4:30 p.m., at the Administration Centre.225 St-Rédempleur Street, Hull (Hull), P.Q., and thereafter until 8:00 p.m., at Gamelin School, 250 Gamelin Boulevard, Hull (Hull), P.Q., on Monday, May 26, 1975.for the purchase of a bond issue of $2,060,000 for the Outaouais Regional School Board, dated June 15, 1975, and redeemable serially from June 15, 1976 to June 15, 1995 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9'/i%, payable semiannually on December 15th and June 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3831 Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juin 1975.Tableau d'amortissement \u2014 $2.060,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 06 1976 .$ 38,000 15 06 1977 .42,000 15 06 1978 .46,000 15 06 1979 .50,000 15 06 1980 .55,000 15 06 1981 .60,000 15 06 1982 .66.000 15 06 1983 .72.000 15 06 1984 .79,000 15 06 1985 .86,000 La commission scolaire régionale de l'Oulaouais se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'Éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicom-mis, entre les mains du ministre des Finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2\" Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec un montant de $717,000 (comprenant les amortissements du 15 juin 1986 au 15 juin 1991 incl.) reporté au 15 juin 1980 et le solde de $749,000 (comprenant les amortissements du 15 juin 1992 au 15 juin 1995 incl.) reporté au 15 juin 1985.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $213,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 juin 1995 au montant de $213,000.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from June 15, 1975.Redemption table \u2014 $2,060.000 \u2014 20 years Date Capital 15 06 1986 .$ 94,000 15 06 1987 .103,000 15 06 1988 .113.000 15 06 1989 .124,000 15 06 1990 .135,000 15 06 1991.148,000 15 06 1992 .163,000 15 06 1993 .178,000 15 06 1994 .195,000 15 06 1995 .213,000 The Outaouais Regional School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to Ihe said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.5.1 to 10-year serial bonds in the amount of $717,000 (comprising the redemptions from June 15, 1986 to June 15, 1991 incl.) carried forward to June 15, 1980 and the balance of $749,000 (comprising the redemptions from June 15, 1992 to June 15, 1995 incl.) carried forward to June 15, 1985 However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds will not be for an amount less than $213,000, and if greater than the latter amount, the said surplus must only comprise one or several complete' annual redemptions, taking into account the redemption\" table appearing in this notice, and starting with the lasr years of redemption excluding the maturity of June 15,1 1995 in the amount of $213,000.However, tenders will be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque. 3832 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $213.000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 juin de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire régionale de l'Oulaouais s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juin 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu de la résolution suivante: 17 février 1975 \u2014 $2,060,000 \u2014 coût excédentaire au 30 juin 1974.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 26 mai 1975, à 8.00 heures du soir.École Gamelin, 250, boul.Gamelin, Hull (Hull), P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Hull, ce 5 mai 1975.Le directeur général.Jean Larsimont.Centre administratif, 225, rue St-Rédempteur, Hull, (Hull), P.Q.Téléphone: 771-73! 1, code 819.60832-o Paroisse de Saint-Félix-du-Cap-Rouge Comté de Chauveau Avis public est par les présentes donné que des soummis-sions cachetées et portant l'inscription «Soumissions pour obligations» seront reçues par le soussigné L.A.Bombardier, secrétaire-trésorier, jusqu'à 4.30 heures p.m., Hôtel de ville, 4264, rue St-Félix, St-Félix-du-Cap-Rouge, comté de Chauveau, P.Q., et par après jusqu'à 7.30 heures du soir, Centre des Loisirs de Cap-Rouge, 4170, rue Roberval.St-Félix-du-Cap-Rouge, comté de Chauveau, P.Q., mercredi, le 28 mai 1975, pour l'achat de $469,000 d'obligations de la paroisse de St-Félix-du-Cap-Rouge, comté de Chauveau, datées du 15 juin 1975 et remboursables en série du 15 juin 1976 au 15 juin 1995 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 972%, payable semi-annuellement les 15 décembre et 15 juin de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juin 1975.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $213,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on June 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Outaouais Regional School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon from and after June 15, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolution: February 17, 1975 \u2014 $2,060,000 \u2014 excess cost as at June 30, 1974.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Monday, May 26, 1975, at 8:00 p.m., at Gamelin School, 250 Gamelin Boulevard, Hull (Hull), P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Hull, May 5, 1975.Jean Larsimont, Director-General.Administration Centre, 225 St-Rédempteur Street, Hull (Hull).P.Q.Telephone: 771-7311, code 819.60832 Parish of Saint-Félix-du-Cap-Rouge County of Chauveau Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, L.A.Bombardier, secretary-treasurer, until 4:30 o'clock p.m., at the Town Hall, 4264 Saint-Félix Street, Saint-Félix-du-Cap-Rouge, County of Chauveau, P.Q., and thereafter until 7:30 o'clock p.m., at the Cap-Rouge Recreational Centre, 4170 Roberval Street.Saint-Félix-du-Cap-Rouge, County of Chauveau, P.Q.on Wednesday, May 28, 1975, for (he purchase of a bond issue of $469,000 for (he Parish of Saint-Félix-du-Cap-Rouge, County of Chauveau, dated June 15.1975 and redeemable serially from June 15, 1976 to June 15, 1995 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 97;%, payable semiannually on December 15th and June 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from June 15, 1975. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3833 Tableau d'amortissement \u2014 $469,000 \u2014 20 ans \tAnnée\t\tCapital 15\t06\t1976 .\t.$ 8,000 15\t06\t1977 .\t.9,000 15\t06\t1978 .\t.10,000 15\t06\t1979 .\t.11,000 15\t06\t1980 .\t.12,000 15\t06\t1981.\t.13,000 15\t06\t1982 .\t.14,000 15\t06\t1983 .\t.15,000 15\t06\t1984 .\t.17,000 15\t06\t1985 .\t.18.000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série là 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en série I à 10 ans avec un montant de $189.000 (comprenant les amortissements du 15 juin 1986 au 15 juin 1992 incl.) reporté au 15 juin 1980 et le solde de $153,000 (comprenant les amortissements du 15 juin 1993 au 15 juin 2015 incl.) reporté au 15 juin 1985.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $73,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant ci-haut, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 juin 1995.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 juin 1995 au montant de $73,000 comprend un solde de $26,500 renouvelable pour une période additionnelle de 20 ans.et échéant comme suit: Année Capital 15 06 1996 .$ 500 15 06 1997 .500 15 06 1998 .500 15 06 1999 .500 15 06 2000 .500 15 06 2001 .1.000 15 06 2002 .1,000 15 06 2003 .1,000 15 06 2004 .1,000 15 06 2005 .1.000 Redemption table \u2014 $469,000 \u2014 20 years Date Capital 15 06 1986 .$ 20,000 15 06 1987 .22,000 15 06 1988 .24,000 15 06 1989 .27,000 15 06 1990 .29,000 15 06 1991 .32.000 15 06 1992 .35,000 15 06 1993 .38,000 15 06 1994 .42.000 15 06 1995 .73,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.5.1 tô 10-year serial bonds in the amount of $189,000 (including the redemptions of June 15, 1986 to June 15, 1992 incl.) carried forward to June 15, 1980 and the balance of $153.000 (including the redemptions of June 15, 1993 to June 15, 2015 incl.) carried forward to June 15, 1985.However, in the case of Ihe last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $73,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of June 15, 1995.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of June 15.1995 in the amount of $73,000 includes a balance of $26,500 renewable for an additional 20-year period, maturing as follows: Date Capital 15 06 2006 .$ 1.000 15 06 2007 .1,500 15 06 2008 .1.500 15 06 2009 .1,500 15 06 2010 .1,500 15 06 2011.2,000 15 06 2012 .2,000 15 06 2013 .2,500 15 06 2014 .2.500 15 06 2015 .3.000 3834 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital el les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $73,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 juin de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La paroisse de St-Félix-du-Cap-Rouge s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juin 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 288 \u2014 $46,000 \u2014 voirie; 289 \u2014 $12,000 \u2014 voirie; 290 \u2014 $117,000 \u2014 voirie; 291 \u2014 $37,400 \u2014 voirie; 292 \u2014 $12,300 \u2014 voirie; 293 \u2014 $9,000 \u2014 voirie; 294 \u2014 $21,300 \u2014 voirie; 295 \u2014 $121.000 \u2014 voirie, 296 \u2014 $29,500 \u2014 voirie; 301 \u2014 $20,000 \u2014 voirie; 307 \u2014 $43,500 \u2014¦ aqueduc, égouts et voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 7.30 heures du soir, mercredi, le 28 mai 1975, Centre des Loisirs de Cap-Rouge, 4170, rue Roberval.St-Félix-du-Cap-Rouge.comté de Chauveau, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Félix-du-Cap-Rouge (Comté de Chauveau), ce 2 mai 1975.Le secrétaire-trésorier.L.A.Bombardier, Hôtel de ville.4264, rue Sl-Félix.St-Félix-du-Cap-Rouge (Chauveau).Québec.Téléphone: 651-1225.code 418.60825-O Commission scolaire de Sainfe-Foy Siège social: 1000 rue Jolibourg Sainte-Foy, Québec Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription «Soumissions pour obligations» seront reçues par le soussigné Robert Julien directeur-général, jusqu'à 4.30 heures de l'après-midi, Centre Administratif, 1000 rue Jolibourg, Sainte-Foy, Québec, P.Q., et par après jusqu'à 8.00 heures du soir.Pavillon Technique, 1135, rue de la Vigerie, Sainte-Foy, Québec, P.Q., mardi le 27 mai 1975 pour l'achat de $565,000 d'obligations de la commission scolaire de Sainte-Foy, datées du 15 juin 1975 et remboursables en série du 15 juin 1976 au 15 juin 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8% ni supérieur à 9'/-%.payable semi- The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $73,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on June 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Parish of Saint-Félix-du-Cap-Rouge agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after June 15, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 288 \u2014 $46.000 \u2014 roads; 289 \u2014 $ 12,000 \u2014 roads; 290 \u2014 $117,000 \u2014 roads; 291 \u2014 $37,400 \u2014 roads; 292 \u2014 $12,300 \u2014 roads; 293 \u2014 $9,000 \u2014 roads; 294 \u2014 $21,300 \u2014 roads; 295 \u2014 $121.000 \u2014 roads, 296 \u2014 $29,500 \u2014 roads; 301 \u2014 $20,000 \u2014 roads; 307 \u2014 $43,500 \u2014 waterworks, sewers and roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held at 7:30 o'clock p.m., on Wednesday, May 28, 1975, at the Cap-Rouge Recreational Centre, 4170 Roberval Street, Saint-Félix-du-Cap-Rouge, County of Chauveau, P.Q.The Council does not bind itself to accept Ihe highest or any of the tenders.Saint-Félix-du-Cap-Rouge (County of Chauveau), May 2, 1975.L.A.Bombardier, Secretary-Treasurer.Town Hall.4264 Saint-Félix Street, St-Félix-du-Cap-Rouge (Chauveau), Québec.Telephone: 651-1225, code 418.60825 Sainte-Foy School Board Head Office: 1000 Jolibourg Street, Sainte-Foy, Québec Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Robert Julien, Director-General, until 4:30 p.m., at the Administration Centre, 1000 Jolibourg Street, Sainte-Foy, Québec, P.Q., and thereafter until 8:00 p.m., at the Pavilion Technique, 1135 De la Vigerie Street, Sainte-Foy.Québec, P.Q., on Tuesday, May 27, 1975, for the purchase of a bond issue of $565,000 for the Sainte-Foy School Board, dated June 15, 1975 and redeemable serially from June 15, 1976 to June 15, 1990 inclusive, with interest at a rate of not less than 8% nor more than 9'/;%, payable semiannually on December 15th and June 15th of each GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n°19 3835 annuellement les 15 décembre et 15 juin de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juin 1975.year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from June 15.1975.Tableau d'amortissement \u2014 $565,000 \u2014 15 ans Date Capital 15 06 1976 .$ 36,000 15 06 1977 .39,000 15 06 1978 .42,000 15 06 1979 .46,500 15 06 1980 .51,500 15 06 1981.55,500 15 06 1982 .60,500 15 06 1983 .66,500 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance 10 ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des 2 termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire de Sainte-Foy.s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juin 1975, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 12-9-49 \u2014 $40.000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 25-3-75 \u2014 $525,000 \u2014 dépenses d'immobilisations.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 27 mai 1975 à 8.00 heures du soir.Pavillon Technique, 1135, rue de la Vigerie.Sainte-Foy, Québec.P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Sainte-Foy, ce 5 mai 1975.Le directeur général.Robert Julien.Centre Administratif, 1000.rue Jolibourg, Sainte-Foy (Québec), P.Q.Tél.: 657-3104, code 418.60836-o Redemption table \u2014 $565.000 \u2014 15 years Date Capital 15 06 1984 .$ 73,000 15 06 1985 .79,000 15 06 1986 .3,000 15 06 1987 .3,000 15 06 1988 .3,000 15 06 1989 .3,000 15 06 1990 .3.500 Moreover, tenders may be sent and will be considered for 10-year short-term bonds.However, tenders should comprise one only of Ihe terms.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at Ihe price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interests are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Sainte-Foy School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon from and after June 15.1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: 12-9-49 \u2014 $40,000 \u2014 loan renewal; 25-3-75 \u2014 $525,000\u2014 capital expenditure.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Tuesday, May 27, 1975, at 8:00 p.m., at the Pavilion Technique, 1135 De la Vigerie Street, Sainte-Foy, Québec, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Sainte-Foy, May 5, 1975.Robert Julien, Director-General.Administration Centre, 1000 Jolibourg Street.Sainte-Foy (Québec), P.Q.Tel.: 657-3104, code 418.60836 3836 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10.1975, Vol.107, No.19 Ventes pour taxes Sales for taxes Ville de Saint-Hubert Avis est par la présente donné que le Conseil municipal de la ville de Saint-Hubert par une résolution en date du 3 février 1975 a ordonné, au soussigné conformément i'i la Loi des cités et villes et de dispositions spéciales de sa charte, de vendre les immeubles ci-après désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues à la ville de Saint-Hubert, avec intérêts et frais et qu'en conséquence lesdits immeubles seront vendus par encan public dans la salle de l'édifice municipal situé à 3350.Grande Allée, le VINGT-SEPTIÈME jour de MAI 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Toutefois, seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels les taxes municipales, tant générales que spéciales de l'année 1974 et des années antérieures auront été payées avant le moment de la vente.City of Saint-Hubert Public notice is hereby given that the Council of the City of St-Hubert has.in virtue of a resolution dated Febiuary 3, 1975, and pursuant to the Cities and Towns Act and to the special provisions of its charter, ordered the undersigned to sell the immoveables hereafter described for payment of arrears of taxes owed to the City of St-Hubert, with interest and costs, and that the said immoveables will consequently be sold by auction on the TWENTY-SEVENTH day of MAY, 1975, at TEN o'clock in the morning, in the municipal building situated at 3350 Grande Allée, St-Hubert.However, those immoveables on which municipal taxes, both special and general, for 1974 and previous years, will have been paid for prior to the moment of the sale, shall be therefrom excluded.ADDENDA Immeuble sujet au droit de retrait / Immoveable subject lo the right of redemption Folio Nom \u2014 Name Lot 0211110-2.Santos Investment Corp.Une partie du lot 53 bornée vers le nord-est par le lot 53-439, vers le sud-est par une partie du lot 53-4 et les lots 53-3, 53-2, vers le sud-ouest par le chemin Chambly.vers le nord-ouest par une autre partie dudit lot 53, mesurant dans ses lignes nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest 191.83 pieds, contenant une superficie de 35,669 pieds carrés.A part of lot 53 bounded towards the northeast by lot 53-439, towards the southeast by a part of lot 53-4 and lots 53-3, 53-2.towards the southwest by the Chambly Road, towards the northwest by another part of said lot 53, measuring 191.83 feet on its northeast, southeast, southwest and northwest lines, containing a superficial area of 35,669 square feet.Première partie / First Part Immeubles sujets au droit de retrait / Immoveables subject to the right of redemption 0124560-4.Monarch Commerce Corp.0160790-2.Manoug Akelian.0186650-8.Pierre Stabili et Dame Antoinette Abandonato, son épouse 0193000-7.Roman J.Isganaitis.Une partie du lot numéro 46 mesurant un arpent de front sur vingt-quatre arpents de profondeur, bornée en front par le chemin Chambly, en profondeur à la décharge Des Fresnes, d'un côté au sud-est à Jean-Baptiste Mercille ou représentants, et de l'autre côté au nord-ouest par François Robert ou représentants.9-290 38-183 45-2 A part of lot number 46 measuring one arpent in front by twenty-four arpents in depth, bounded in front by Chambly Road, in depth by the Des Fresnes outlet, on one side on the southeast by the property owned by Jean-Baptiste Mercille or representatives, and on the other side on the northwest by the property owned by François Robert or representatives.0195700-0.C.B.M.Development Inc.47-2 0240990-2.John Kastoris et Dame Ageliki 65-15 Loukovitis, son épouse 0241660-0.Dame Penelope Gialeli, épouse 65-77 John Mavroulis 0270070-3.Edmond Sabourin, Jr.70-3 0276720-0.Adrien Langlais et Dame Louise 72-73 Poirier, son épouse 0344560-8.Irvine G.Wood.90-48 0344590-5.Irvine G.Wood.90-49 0419100-3.Gordon R.Lancaster.102-683,684 0419160-7.Gordon R.Lancaster.102-693,694 0470490-4.Dame Mary Margaret Littlejohn 113-1599, 1600 épouse Ernest Douris GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1975.107' année.n° 19 3837 Folio Nom \u2014 Name Lot 0491140-0.Reynold Skerrett.118-193 0491230-9.Henri Demers, faisant affaires seul 118-203 sous les nom et raison sociale de « 2-B-5 Enrg.a 0491720-9.Antonio Giacomodonato, Dame 118-262 Angelina Di Lazzaro, Antonio Borrelli et Dame Maria Di Lazzaro 0536S70-9.Condor Construction Co.Ltd.130-67 0536900-4.Condor Construction Co.Ltd.130-70 0538410-2.Romstan Ltd.Une partie du lot 130 mesurant 80 pieds de largeur sur une A part of lot 130 measuring 80 feet in width by a depth of profondeur de 120 pieds, bornée en front au nord-est par le 120 feet, bounded in front on the northeast by Chambly Road, chemin Chambly, en arrière au sud-ouest et d'un côté nu at the rear on the Southwest and on one side on the northwest nord-ouest par le résidu dudit lot 130 ou ses subdivisions, et by the remainder of said lot 130 or its subdivisions, and on de l'autre côte au sud-est par une partie du lot 129.the other side on the southeast by a part of lot 129.0538721-2.Les Jardins Monte Carlo Inc.Une partie du lot 130 mesurant 391.8 pieds de largeur en A part of lot 130 measuring 391.8 feet in width in front on front sur le boulevard Cousinenu, 412.1 pieds de largeur en Cousineau Boulevard, 412.1 feet in width at the rear by a arrière, sur une profondeur de 115.5 pieds dans sa ligne sud- depth of 115.5 feet in its southeast line, 100 feet on its north-est, de 100 pieds dans sa ligne nord-ouest, et de 31.6 pieds west line and 31.6 feet on its north line along an arc of a circle dans sa ligne nord le long d'un arc de cercle ayant un rayon having a radius of 20 feet; bounded in front on the northeast de 20 pieds; bornée en front au nord-est par le boulevard by Cousineau Boulevard (130-1), at the rear on the southwest Cousineau (130-1), en arrière au sud-ouest par parties dudit by parts of said lot 130, on one side on the southeast by a part lot 130, d'un côté au sud-est par une partie du lot 129, et au of lot 129, and on the northwest and north by Avon Street, nord-ouest par la rue Avon, ainsi qu'au nord.0542410-6.Gilbert Gagné.132-46-2 0542550-9.Roman J.Isganaitis.La partie nord-est du lot 132-52 mesurant 96 pieds de lar- The northeast part of lot 132-52 measuring 96 feet in width geur sur une profondeur de 164 pieds, bornée en front au by a depth of 164 feet, bounded in front on the southeast by sud-est par la rue-Howard, en arrière au nord-ouest par le lot Howard Street, at the rear on the northwest by lot 133 or its 133 ou ses subdivisions, d'un côté au nord-est par le lot 132-53 subdivisions, on one side on the northeast by lot 132-53 and et de l'autre côté au sud-ouest par le résidu dudit lot 132-52.on the other side on the southwest by the remainder of said lot 132-52.0544450-0.Guy Archambault.La partie sud-est du lot 133-62 mesurant 100 pieds de lar- The southeast part of lot 133-62 measuring 100 feet in geur sur une profondeur de 75 pieds, bornée au sud-est par width by a depth of 75 feet, bounded on the southeast by a une rue (133-80), en arrière au nord-ouest par le résidu dudit street (133-80), at the rear on the northwest by the remainder lot 133-62.d'un côté au nord-est par partie du lot 133-61 et of said lot 133-62.on one side on the northeast by part of de l'autre côté au sud-ouest par le lot 133-63.lot 133-61 and on the other side on the southwest by lot 133-63.0545870-8.C.B.M.Development Inc.133-230; 133-231-1 0546490-4 .Frank Browman.133-300, 301, 302 0546940-8.Michael Arthur Zakaib, George 133-350,351,352 Zakaib, Dame Marina Zakaib épouse Floyd David, John Wesley Zakaib, Lome John Zakaib et Dame Denise Zakaib épouse de Kelly Arrey 0547990-2.Dlle Angeliki Marinou.133-476 et la moitié sud-ouest, du lot 133-475; cettedite 133-476 and the southwest half of lot 133-475; said half moitié mesurant 25 pieds de largeur sur une profondeur de measuring 25 feet in width by a depth of 100 feet, bounded 100 pieds est bornée au nord-ouest par la rue Prince-Charles, on the northwest by Prince-Charles Street, on the southwest au sud-ouest par le lot 133-476, au nord-est par le résidu dudit by lot 133-476, on the northeast by the remainder of said lot 133-475 et en arrière par la ligne arrière dudit lot 133-475.lot 133-4-5, and at the rear by the back line of said lot 133- 475.0548110-6.Percival Ralph Martin.133-488 0548120-5.Percival Ralph Martin.133-489 0548220-3 .Evangelos Alexopoulos-.133-494 0548300-3 .Ernest Millichamp et / and Douglas Millichamp faisant affaires ensemble sous les nom et raison sociale de Millichamp, Contractors / carrying on business under the trade name of Millichamp Contractors.La partie sud-ouest du lot 133-498 mesurant 50 pieds de The southwest part of lot 133-498 measuring 50 feet in largeu^ur une%fondeur de 100 pieds, bornée en front par width by a depth of 100 feet, boimdedun fron by Pa^k Street la rm Park en arrière nar le lot 133-487, d'un côté par le lot at the rear by lot 133-487, on one side by ot 133-499, and 133 49^érde 1'auTre cô?é par le résidu audit lot 133-498; et on the other side by the remainder of said lot 133-498; and 3838 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10.1975.Vol.107, No.19 Folio Nom \u2014 Name Lot la partie nord-est du lot 133-499 mesurant 25 pieds de largeur sur une profondeur de 100 pieds, bornée en front par la rue Park, en arrière par le lot 133-488, d'un côté par le lot 133-498 et de l'autre côté par le résidu dudit lot 133-499.the northeast part of lot 133-499 measuring 25 feet in width by a depth of 100 feet, bounded in front by Park Street, at the rear by lot 133-488, on one side by lot 133-498 and on the other side by the remainder of said lot 133-499.0548610-5.Nicolaos Mastrogianakos.133-532,533 0549070-1.Robert Stevenson, Jr.et Dame I.134-25 Charnley we.R.L.Stevenson 0549510-6.Frederick Schueppel.134-52 0549620-3.James George Dimis.134-58 0549680-7.Friedrich Schuppel.La partie sud-ouest du lot 134-61 mesurant 50 pieds de largeur sur une profondeur de 100 pieds, bornée en front au nord-ouest par une rue (134-64), en arrière au sud-est par le lot 133 ou ses subdivisions, d'un côté au sud-ouest par le lot 134-62 et de l'autre côté au nord-est par le résidu dudit lot 134-61.The southwest part of lot 134-61 measuring 50 feet in width by a depth of 100 feet, bounded in front on the northwest by a street (134-64), at the rear on the southeast by lot 133 or its subdivision, on one side on the southwest by lot 134-62 and on the other side on the northeast by the remainder of said lot 134-61.0549910-8.Fred (Frank) Schueppel.134-75-1 0550190-3.Athanasios Michaelidis.La moitié nord-est du lot 134-105 mesurant 50 pieds de largeur sur une profondeur de 100 pieds, bornée en front au sud-est par la rue Adélaïde (134-64), au nord-ouest par le lot 134-219, d'un côté au nord-est par le lot 134-106 et de l'autre côté par le résidu dudit lot 134-105.0554420-0.The School Commissioners for the Municipality of St.Hubert, in the County of Chambly 0554660-1 .The School Commissioners for the Municipality of St.Hubert, in the County of Chambly 0554670-0.The School Commissioners for the Municipality of St.Hubert, in the County of Chambly 0564890-2.Peter Leroy Howard et Dame Enid Matilda Bishop veuve Barton Seymour Leroy Howard 0564900-9.Peter Leroy Howard et Dame Enid Matilda Bishop veuve Barton Seymour Leroy Howard 0564910-8.Peter Leroy Howard et Dame Enid Matilda Bishop veuve Barton Seymour Leroy Howard 0565660-8 René Lemieux.136-944 à 949 0565700-2.0565710-1.René Lemieux.136-960 à 962 et l'extrême partie nord-ouest des lots 136-990 et 991, mesurant un pied de profondeur dans ses lignes nord-est et sud-ouest par une largeur de 50 pieds dans ses lignes nord-ouest et sud-est, bornée au nord-ouest par les lots 136-961 et 962, au nord-est par une partie du lot 136-992.au sud-est par le résidu desdits lots 136-990 et 991, et au sud-ouest par une partie du lot 136-989.The northeast half of lot 134-105 measuring 50 feet in width by a depth of 100 feet, bounded in front on the southeast by Adélaïde Street (134-64), on the northwest by lot 134-219, on one side on the northeast by lot 134-106 and on the other side by the remainder of said lot 134-105.134-1-238, 239 134-1-266 à 271 134-1-272 à 275 136-774, 775 136-776, 777 136-778.779 136-960 to 962 at the extreme northwest part of lots 136-990 and 991, measuring one foot in depth on its northeast and southwest lines by a depth of 50 feet on its northwest and southeast lines, bounded on the northwest by lots 136-961 and 962, on the northeast by a part of lot 136-992, on the southeast by the remainder of said lots 136-990 and 991, and on the southwest by a part of lot 136-989.0569650-5.John Lambrinos.0569660-4.John Lambrinos .0569750-3.Dame Maria Gramatikaki épouse Nicolaos Mastrogianakos 0569790-9.Dame Joanna Asimakopoulos et Peter Balodimas, son époux 0569880-8.John Vlachos.0573890-1 .Les Entreprises B.M.C.Inc.0573900-8.Les Entreprises B.M.C.Inc.0574070-9.Jean-Paul Allaire.0577310-6.Caisse d'Économie Angus.0579140-5.Stefan Chojnacki et Dame Maria Szymanski, veuve Martin Gorze- lanczyk 0579300-5.Dame Micheline Merle, épouse Constantin L.Valceanu 0579310-4.Dame Micheline Merle, épouse Constantin L.Valceanu 0586864-1.Fred Schueppel.142-510 142-511 142-520 142-524 142-533 143-434 143-435 143-452 145-313 147-102 147-118 147-119 154-1147 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1975.107' année, n° 19 Folio Nom \u2014 Xa me Lot 0587160-3.Hotel Aviation Inc.155-1001 à 1026, il distraire des lots 155-1011 à 1016 la partie expropriée par le ministère de la Voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 77471, 312753 et 352077.0607390-2.René Lemieux.155-1001 to 1026, to withdraw from lots 155-1011 to 1016 the part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec under the terms of the deeds registered at the County of Chambly Registry Office under numbers 77471, 312753 and 352077.157-39.40 Par.St-Hubert \u201e____.\u201e _ ._ 224-37.38 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0616900-7.St-Hubert Protestant School Board.160-2 à distraire la partie vendue Ma Ville de Saint-Hubert 160-2 to withdraw the part sold to the City of St-Hubert under the terms of a deed registered at the County of Chambly Registry Office under number 276188.aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous Je numéro 276188.0617330-6.Gerald McDonough.160-91,92 061925O-4.Claude Poudrier.0620740-1 .Harold Booth.0633473-4 .James Trounson et Dame Griselda McBride, son épouse 0637440-9.Les Habitations BCP Limitée .0637580-2.Suresh Kumar Gupta.0640600-3.Dame Rhoda Gore épouse Joseph Steele 0653260-0.John Prescott.Une partie du lot 169-89 mesurant 173 pieds de largeur sur une profondeur de 125 pieds, bornée en front par une rue (169-102).en arrière par le lot 169-56, d'un coté au nord-est par le lot 169-90 et de l'autre côté par le résidu dudit lot 169-89.160-394 161-6 164-111 164-397 164-443 166-11.12 A part of lot 169-89 measuring 173 feet in width by a dept of 125 feet, bounded in front by n street (169-102), at the rear by lot 169-56, on one side on the northeast by lot 169-90 and on the other side by the remainder of said lot 169-89.0657270-6.John Sperdekos et Dame Polly 169-194 Papadakos, veuve Athanasias K.Sperdakos, Constantinos K.Sper-dakos, Constantinos Papadakos et Constantinos Peter Sperdakos, ès-qualité d'exécuteurs-testamentaires et fiduciaires de Athanasias K.Sperdakos 0661330-1.Denis Jutras.171-595.596 0669130-7.Adolphe Simard.172-165:173-71 0670390-4.The Protestant School Municipality 172-277.278 of Pinehurst and East Greenfield 0670400-1 .The Protestant School Commission- 172-279 à / to 282 ers for the Municipality of Pinehurst and East Greenfield 0682847-9.Demetrios Papageorgiou.174-589 0707250-7.Artists Circle Ltd.Partie du lot 178 se décrivant comme suit: Parts of lot 178 described as follows: a) Partie du lot 178, de forme triangulaire, bornée en front (a) Part of lot 178 being of triangular figure, bounded in vers le sud-ouest dans sa ligne B-A par une autre partie du lot front towards the southwest in its line B-A by another part 178 (chemin de la Côte Noire) et mesurant 64.6 pieds; vers le of lot 178 (chemin de la Côte Noire) and measuring 64.6 feet; nord-ouest, dans sa ligne A-C, par partie du lot originaire 177 towards the northwest, in its line A-C, by part of original lot et mesurant 291.9 pieds et vers le sud-est, dans sa ligne C-B, 177 and measuring 291.9 feet and towards the southeast, in par une autre partie du lot 178 expropriée pour une voie de its line C-B by another part of lot 178 expropriated for a service & la Route de contournement de la rive-sud et mesurant service road to Route de contournenient de la rive-sud and 301.9 pieds; couvrant une superficie de 9,433 pieds carrés.measuring 301.9 feet; containing a superficial area of 9,433 square feet; 6) Une autre partie dudit lot 178, de figure irrégulière et (6) Another part, of said lot 178 being of irregular figure bornée en front vers le sud-ouest dans ses lignes G-F, F-E et and bounded in front towards the southwest in its line G-F, E-D, par le Chemin de la Côte Noire (partie 178) et mesurant F-E, and E-D, by Chemin de la Côte Noire (Pt.178) and 1.7 pieds dans sa ligne G-F, 300.9 pieds dans sa ligne F-E et measuring 1.7 foot in its line G-F, 300.9 feet in its line F-E 22 pieds dans sa ligne E-D; vers le nord-ouest dans ses lignes and 22 feet in its line E-D: towards the northwest in its lines D-P et P-O par partie du lot 178-1 (propriété de l'Hydro- D-P and P-O by part of lot 178-1 (property of Hydro Québec) Québec) et mesurant 675.15 pieds dans sa ligne D-P et 5,389.1 and measuring 675.15 feet in its line D-P and 5.389.1 feet in its pieds dans sa ligne P-O; vers le nord, dans sa ligne O-N, vers line P-O; towards the north, in its line O-N, towards the le nord-ouest dans ses lignes N-M et M-L par une autre partie northwest in its lines N-M and M-L by another part of lot du lot 178 (propriété du ministère de la voirie de la province 178 (property of the Department of Roads of the Province of de Québec, Route de contournement de la rive sud) et mesurant Québec, Route de contournement de la rive sud) and meas-139.4 pieds dans sa ligne O-N, 227.4 pieds dans sa ligne N-M uring 139.4 feet in its line O-N, 227.4 feet in its line N-M et 590.4 pieds dans sa ligne M-L; vers le nord-est, dans sa and 590.4 feet in its line M-L ; towards the northeast, in its ligne L-K, par le boulevard Maricourt (ptie 178) et mesurant line L-K, by Mancourt Boulevard (Pt.178) and measuring 382.7 pieds et vers le sud-est.dans sa ligne K-G, par une 382.7 feet and towards the southeast, in its line K-G, by partie du lot 179 et mesurant 7,002.11 pieds; couvrant une a part of lot 179 and measuring 7,002.11 feet; containing a superficie de 3.144,426 pieds carrés.superficial area of 3,144,426 square. 3840 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Folio Nom \u2014 Name Lot A distraire cependant la partie expropriée par le ministère des transports aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 414849.0713880-3.Artists Circle Ltd.Une partie du lot 179 se décrivant comme suit: Partie du lot 179, de forme irrégulière et bornée en front vers le sud-ouest dans sa ligne H-G par le Chemin de la Côte Noire (ptie 179) et mesurant 384.10 pieds vers le nord-ouest, dans sa ligne G-K parla partie du lot 178 et mesurant 7,002.11 pieds vers le nord-est, dans sa ligne K-J par le boulevard Maricourt (ptie 179) et mesurant 382.6 pieds et vers le sud-est, dans ses lignes J-I et I-H par le résidu du lot 179 et mesurant 5,515 pieds dans sa ligne J-I et 1.536.1 pieds dans sa ligne 1-H.Couvrant une superficie de 2.713,120 pieds carrés.A distraire cependant la partie expropriée par le ministère des transports aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 414849.To withdraw, however, the part expropriated by the Department of Transport under the terms of a deed registered at the County of Chambly Registry Office under number 414849.A part of lot 179 described as follows: Part of lot 179 of irregular figure and bounded in front towards the southwest in its line H-G by Chemin de la Côte Noire (Pt.179) and measuring 384.10 feet towards the northwest, in its line G-K by the part of 178 and measuring 7,002.11 feet towards the northeast, in its line K-J, by Maricourt Boulevard (Pt.179) and measuring 382.6 feet and towards the southeast, in its lines J-I and I-H by the remaining part of lot 179 and measuring 5,515 feet in its line J-I and 1,536.1 feet in its line I-H.Containing a superficial area of 2,713,120 square feet.To withdraw, however, the part expropriated by the Department of Transport under the terms of a deed registered at the County of Chambly Registry Office under number 414849.0719350-1 .Guy Côté.Une partie du lot 180 mesurant 96.67 pieds de largeur sur une profondeur de 768 pieds, bornée au sud-ouest par le Chemin de la Côte Noire, en arrière au nord-est par une autre partie dudit lot 180, d'un côté au sud-est par partie dudit lot 180 appartenant à René Perron, ou représentants, et de l'autre côté au nord-ouest par une autre partie dudit lot 180 appartenant à Dame Lise Favreau, ou représentants.La ligne nord-ouest de cette partie est parallèle et distante de 96.67 pieds de la ligne de division entre les lots 179 et 180 mesurée le long du Chemin de la Côte Noire.0805450-4.Santos Investment Corp.A distraire les parties vendues aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 391555 et 413841.A part of lot 180 measuring 96.67 feet in width by a depth of 768 feet, bounded on the southwest by Chemin de la Côte Noire, at the rear on the northeast by another part of said lot 180, on one side on the southeast by part of said lot 180 belonging to René Perron or representatives, and on the other side on the northwest by another part of said lot 180 belonging to Mrs.Lise Favreau or representatives.The northwest line of this part is parallel to and located at a distance of 96.67 feet from the dividing line between lots 179 and 180 measured along Chemin de la Côte Noire.196 Less and to withdraw the parts sold under the terms of the deeds registered at the County of Chambly Registry Office under numbers 391555 and 413841.0903201-2.J.-Léo St-Pierre.204-34 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0903202-0.J.-Léo St-Pierre 0904113-8 0905551-8.Dame Huguette Rose, épouse Charles Bédard 0905552-6.Dame Huguette Rose, épouse Charles Bédard 0908501-0.Roland Labelle.204-35 Par.St-Antoine-de-Longueuil Roland Felx.,._.^____ 204-373 Par.St-Antoine-de-Longueuil.209-853 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0909501-9.Les Immeubles Roluc Inc.0909502-7.Les Immeubles Roluc Inc.0909503-5.Les Immeubles Roluc Inc.0909504-3.Les Immeubles Roluc Inc.0909505-0.Les Immeubles Roluc Inc.0909506-8.Les Immeubles Roluc Inc.0909507-6.Les Immeubles Roluc Inc.0912616-0.Dame Jeanne D'Arc Lord épouse Guy Brouillet.Un emplacement composé: a) d'une partie du lot 209, paroisse St-Antoine-de-Longueuil, de figure irrégulière, mesurant dans ses lignes nord-est 22 pieds et 40.5 pieds, dans ses lignes sud-est 20.23 pieds, 2.96 pieds, 71.54 pieds, dans sa ligne sud-ouest 44.19 pieds et clans sa ligne nord-ouest 100 pieds, bornée vers le nord-est par une partie des lots 209-862, 209-721 et 209-722 (rue Des Cèdres), vers le sud-est par une partie des lots 209-721 et 209-794 (rue Jean XXIII), vers le sud-ouest par une partie du lot 209-853 et vers le nord-ouest par une partie du lot 209-855, contenant une superficie de 4,371 pieds carrés; b) d'une partie du lot 209-721, paroisse St-Antoine-de-Longueuil, de figure irrégulière, mesurant dans sa ligne nord-est 9.83 pieds, dans sa ligne est 19.18 pieds mesuré le long d'un arc de cercle engendré par un rayon de 25.17 pieds, dans sa ligne sud-est 18.09 pieds, dans sa ligne sud-ouest 28 pieds, dans sa ligne nord-ouest 20.23 pieds et bornée vers le nord-est et l'est 209-852 Par.St-Antoine-de-Longueuil.212-1216, 1217, 1218 Par.St-Antoine-de-Longueuil.199-191, 192 Par.St-Antoine-de-Longueuil.199-189, 190 Par.St-Antoine-de-Longueuil.199-187, 188 Par.St-Antoine-de-Longueuil.199-185, 186 Par.St-Antoine-de-Longueuil.199-183, 184 Par.St-Antoine-de-Longueuil.199-181, 182 Par.St-Antoine-de-Longueuil.199-179.180 Par.St-Antoine-de-Longueuil.An emplacement comprising: (a) a part of lot 209, Parish of St-Antoine-de-Longueuil, of irregular configuration, measuring 22 feet and 40.5 feet on its northeast lines, 20,23 feet, 2.96, 71.54 feet on its southeast lines, 44.19 feet on its southwest line and 100 feet on its northwest line, bounded towards the northeast by a part of lots 209-862,209-721 and 209-722 (Des Cèdres Street), towards the southeast by a part of lots 209-721 and 209-794 (Jean XXIII Street), towards the southwest by a part of lot 209-853 and towards the northwest by a part of lot 209-855, covering a surface area of 4,371 square feet; (b) a part of lot 209-721, Parish of St-Antoine-de-Longueuil, of irregular configuration, measuring 9.83 feet on its northeast line, 19.18 feet on its east line, measured along an arc of a circle having a radius of 25.17 feet, 18.09 feet on its southeast line.28 feet on its southwest line, 20.23 feet on its northwest line and bounded towards the northeast and the east by GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1975.107' année, n\" 19 3841 Folio Nom \u2014 Name Lot par une autre partie du lot 209-721 (rue Des Cèdres) vers le sud-est par une partie du lot 209-722, vers le sud-ouest et nord-ouest par une partie du lot 209, contenant une superficie de 593 pieds carrés ; c) d'une partie du lot 209-722, paroisse St-Antoine-de-Longueuil, de figure irrégulière, mesurant dans sa ligne est 21.89 pieds mesuré le long d'un arc de cercle engendré par un rayon de 25.17 pieds, dans sa ligne sud-ouest 12.15 pieds, dans sa ligne nord-ouest 18.09 pieds et bornée vers l'est par une autre partie du lot 209-722 (rue Jean XXIII), vers le sud-ouest par une partie du lot 209 et vers le nord-ouest par une partie du lot 209-721, contenant une superficie de 146 pieds carrés; d) Du lot numéro 209-855-1 Paroisse St-Antoine-de-Longueuil.another part of lot 209-721 (Des Cèdres Street), towards the southeast by a part of lot 209-722, towards the southwest and the northwest by a part of lot 209, covering an area of 593 square feet; (c) a part of lot 209-722, Parish of St-Antoine-de-Longueuil, of irregular configuration, measuring 21.89 feet on its east line measured along an are of a circle having a radius of 25.17 feet, 12.15 feet on its southwest line, 18.09 feet on its northwest line and bounded towards the east by another part of lot 209-722 (Jean XXIII Street), towards the southwest bv a part of lot 209 and towards the northwest by a part of lot 209-721, covering an area of 146 square feet; W) Lot number 209-855-1, Parish of St-Antoine-de-Longueuil.0913855-3 0923512-8 0923515-1 0930315-7.0930317-3.Real Schink et Hugues Schink Fernand Gadbois.Fernand Gadbois.Dame Linda Martison, épouse Kenneth Loucier Dame Linda Martison, épouse Kenneth Loucier Jean-Paul Cousineau.207-84 Par.St-Antoine-de-Longueuil.203-100-2; 203-101, 102 Par.St-Antoine-de-Longueuil.203-98.99; 203-100-1 Par.St-Antoine-de-Longueuil.208-899 Par.St-Antoine-de-Longueuil.208-900 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0931205-9.Un emplacement composé : a) du lot 234-274, paroisse St-Antoine-de-Longueuil, dont il faut distraire la partie suivante: En partant delà rue Gladstone et en mesurant quinze pieds sur la ligne de division des lots 234-274 et 275 et puis à angle droit, vers le nord-est pour une distance de 1.4 pieds, puis tournant vers le nord-ouest et en mesurant une distance de 27 pieds et 10 pouces jusqu'à un point situé à 10 pouces au nord-ouest de la ligne de division desdits lots 234-274 et 275 et en tournant à angle droit vers le sud-ouest et en mesurant une distance de 6 pouces pour rejoindre ladite ligne de division, ladite partie bornée au sud-ouest par une partie dudit lot 234-275, au nord-est, au nord-ouest et au sud-est par d'autres parties dudit lot 234-274; b) d'une partie du lot 234-273, paroisse St-Antoine-de-Longueuil, mesurant 1 pied de largeur sur une profondeur de 90 pieds, bornée en front au sud-est par la rue Gladstone, en arrière au nord-ouest par un ruelle (234-278), d'un côté au sud-ouest par le lot 234-274 et de l'autre côté par le résidu dudit lot 234-273.An emplacement comprising: (a) Lot 234-274, Parish of St-Antoine-de-Longueuil, from which shall be withdrawn the following part: Starting from Gladstone Street and measuring fifteen feet on the dividing line between lots 234-274 and 275, thence at right angles, northeasterly over a distance of 1.4 feet, thence turning northwesterly and measuring a distance of 27 feet 10 inches to a point located 10 inches away on the northwest of the dividing line between said lots 234-274 and 275 and turning at right angles southwesterly and measuring a distance of 6 inches to meet the said dividing line; the said part is bounded on the southwest by a part of said lot 234-275, on the northeast, the northwest and the southeast by other parts of said lot 234-274; (6) A part of lot 234-273.Parish of St-Antoine-dc-I.on-gueuil, measuring 1 foot in width by 90 feet in depth, bounded in front one the southeast by Gladstone Street, in rear on the northwest by a lane (234-278).on one side on the southwest by lot 234-274 and on the other side by the remainder of the said lot 234-273.0932630-7.Jean-Guy Brulotte.0934106-6.Clément Roy.0936677-4.Gaby Sparapani.0939586-4.Dame Nathalie Gingues épouse Léo Martel 0944503-2.Dame Edna May Coleman épouse Kennoth Hastings 0945857-1.Raymond Desrosiers.0946150-0.Claude Gervais.0948251-4.Modlivco Inc.Une partie du lot 113.paroisse St-Antoine-de-Longueuil, bornée au nord par partie du lot 113 (Boulevard Sir Wilfrid Laurier, route no 9), au nord-est par le lot 113-5, au sud-est par les lots 113-1, 113-2, 113-3 et 113-5, au sud-ouest par partie des lots 210 et 211, et au nord-ouest par une partie des lots 114, 114-1, 114-2 et 113-5, et mesurant dans ses lignes nord 87.4 pieds.475.4 pieds et 34.2 pieds, dans sa ligne nord-est 93 pieds (le long du lot 113-5) dans ses lignes sud-est 155 pieds et 3.105 pieds, dans sa ligne sud-ouest 591 pieds et dans ses lignes nord-ouest 211 pieds (le long du lot 113-5) et 2,611.4) pieds, contenant une superficie de 44.32 arpents; à distraire de cette partie un emplacement de figure rectangulaire mesurant 100 pieds dans ses lignes nord-est et sud-ouest, et 70 pieds dans ses lignes sud-est et nord-ouest, la ligne nord-est de 1 emplacement déduit est située à une distance de 315 pieds de la route 9 (Boulevard Sir Wilfrid Laurier).Ladite distance de 315 pieds étant mesurée en direction sud-ouest, parallèle à la ligne de division des lots 113 et 114, et a une distance de 384 pieds de celle-ci.205-73, 74 Par.St-Antoine-de-Longueuil.233-88 Par.St-Antoine-de-Longueuil.203-92.93 Par.St-Antoine-de-Longueuil.206-53 Par.St-Antoine-de-Longueuil.203-167, 108 Par.St-Antoine-de-Longueuil.204-537 Par.St-Antoine-de-Longueuil.204-427 Par.St-Antoine-de-Longueuil.A part of lot 113, Parish of St-Antoine-de-Longueuil, bounded on the north by a part of lot 113 (Sir Wilfrid Laurier Boulevard, Highway No.9), on the northeast by lot 113-5, on the southeast by lots 113-1.113-2, 113-3 and 113-5, on the southwest by parts of lots 210 and 211, and on the northwest by a part of lots 114, 114-1, 114-2 and 113-5.and measuring on its north lines87.4 feet, 475.4 feet and 34.2 feet, 93 feet on its northeast line (along lot 113-5).on its southeast lines 155 feet and 3,105 feet, on its southwest line 591 feet and on its northwest lines 211 feet (along lot 113-5) and 2,611.4 feet, covering an area of 44.32 arpents; to be withdrawn from said part an emplacement of rectangular configuration measuring 100 feet on its northeast and southwest lines, and 70 feet on its southeast and northwest lines ; the northeast line of the emplacement withdrawn is located at a distance of 315 feet from Highway 9 (Sir Wilfrid Laurier Boulevard).The said distance of 315 feet being measured in a southwest direction and being parallel and distant from the division line between lots 113 and 114, a distance of 384 feet. 3842 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Folio Nom ¦\u2014 Name I.ol Modlivco Inc.0948791-9.Une partie du lot 113-3.paroisse St-Antoine-de-Longueuil bornée au nord par les lots 113-2 et 113-1.au sud-est par le lot 156, paroisse de St-Hubert, au sud par partie du lot 113-3, et au nord-ouest par une partie du lot originaire 113 et par le lot 113-2, mesurant dans ses lignes nord 117.24 pieds et 107.63 pieds, dans sa ligne sud-est 2,320 pieds, dans sa ligne sud 227.9 pieds, et dans ses lignes nord-ouest 250 pieds et 2,070 pieds, contenant une superficie de 492,388 pieds carrés.A part ot lot 113-3, Parish of St-Antoine-de-Longueuil, bounded on the north by lots 113-2 and 113-1.on the southeast by lot 156, Parish of St-Hubert, on the south by a part of lot 113-3, and on the northwest by a part of original lot 113 and by lot 113-2, measuring 117.24 feet and 107.63 feet on its north lines; 2,320 feet on its southeast line; 227.9 feet on its south line, and 250 feet and 2,070 feet on its northwest lines; covering an area of 492,388 square feet.0952232-7 .Jean-Louis Descarrega.233-611 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0954514-6.Valtes Inc.et.Ville de St-Hubert.235-627, 628 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0954031-8.Dame Marielle Dupont veuve Gilles 235-182, 183 Par.St.-Antoine-de-Longueuil.Bernard 0955214-2.Roger Gingras.233-294 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0958705-6.Les Immeubles Roluc Inc.199-144.145 Par.St-Antoine-de-Longueuil.A distraire du lot 199-145 la partie expropriée par le minis-tire de la voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 289134 et 336551.To be withdrawn from lot 199-145 the Part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec, under the terms of deeds registered at the County of Chambly Registry Office, under numbers 289134 and 336551.0958707-2.Les Immeubles Roluc Inc.199-142, 143 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0958709-8.Les Immeubles Roluc Inc.199-140, 141 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0968711-4.Les Immeubles Roluc Inc.199-138, 139 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0958713-0.Les Immeubles Roluc Inc.199-136, 137 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0958715-5.Les Immeubles Roluc Inc.199-134, 135 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0968717-1.Les Immeubles Roluc Inc.0960340-8.Guiseppe Perri et Francesco Perri.0960342-4.Guiseppe Perri et Francesco Perri.0961675-6.Entreprises Wary Inc.0961677-2.Entreprises Wary Inc.0961679-8.Entreprise Wary Inc.0961681-4.Entreprises Wary Inc.0961683-0.Entreprises Wary Inc.0961685-5.Entreprises Wary' Inc.199-132, 133 Par.St-Antoine-de-Longueuil.208-47-1, 208-48-1.208-49-1, 208-50-1, 208-51-1 Par.St-Antoine-de-Longueuil.208-47-2, 208-48-2, 208-49-2, 208-50-2, 208-51-2 Par.St-Antoine-de-Longueuil.236-694.695; 235-241 Par.St-Antoine-de-Longueuil.236-696.697; 235-239.240 Par.St-Antoine-de-Longueuil.236-698.699; 235-237.238 Par.St-Antoine-de-Longueuil.236-700, 701 ; 235-235, 236 Par.St-Antoine-de-Longueuil.236-702.703; 235-233, 234 Par.St-Anloine-de-Longueuil.236-704 a/io 706; 235-230 a/lo 232 Par.St-Antoine-de-Longueuil.200-425 Par.St-Antoine-de-Longueuil.206-126 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0900507-6.Gilles Robichaud.0966606-6.Guiseppe Morabito, et Dame Catherina Rodi, son épouse 0973816-2.Perri Holding Inc.0976936-8.Entreprises Wary Inc.212-185 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0975949-9.Entreprises Wary Inc.212-183 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0975951-5.Entreprises Wary Inc.0975955-6.Entreprises Wary Inc.0976321-0.Henry Harrison.Une partie du lot 212-250.paroisse St-Antoine-de-Longueuil, mesurant 250 pieds de largeur sur une profondeur de 104 pieds, bornée au nord-ouest par la rue Robillard (212-210), en arriére au sud-est par partie du lot 212, d'un côté au sud-ouest par le résidu dudit lot 212-25U et de l'autre côté au nord-est par le lot 212-251.200-75, 76 Par.St-Antoine-de-Longueuil.212-184 Par.St-Antoine-de-Longueuil.212-186 Par.St-Antoine-de-Longueuil.A part of lot 212-250, Parish of St-Antoine-de-Longueuil, measuring 250 feet in width by 104 feet in depth, bounded on the northwest by Robillard Street (212-210).in rear on the southeast by a part of lot 212, on one side on the southwest by the remainder of the said lot 212-250 and on the other side on the northeast by lot 212-251.0977833-3.Yvon Hamel et Michel Lefebvrc .0980709-4.Edward MacKinnon.0985240-1.Dominique et Marcel Scott alias Sciotto 0992101-0.Les Immeubles Roluc Inc.A distraire du lot 199-194 la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 289134 et 336551.207-385 Par.St-Antoine-de-Longueuil.212-1481 Par.St-Antoine-de-Longueuil.233-493 Par.St-Antoine-de-Longueuil.199-194.195, 196 Par.St-Antoine-de-Longueuil.To be withdrawn from lot 199-194 the part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec, under the terms of deeds registered at the County of Chambly Registry Office under numbers 289134 and 336551.!95~ZVe* Immeubles Roluc Inc.199-197.198 Par.St-Antoine-de-Longueuil.0992150-3.Jean-Louis Bradette.202-90,91.92 Par.St-Antoine-de-Longueuil. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3843 Deuxième partie / Second Part Immeubles non-sujets au droit de retrait / Immoveable not tubject to the right of redemption Folio Nom \u2014 Name Lot 0024900-3.Dlle Theodosia Marouda.226-391 Par.Ste-Famille-de-Boucherville.0025210-6.Cary Mossaidis et Dame Eray 226-422 Par.Ste-Famille-de-Boucherville.Kambourogtou, son épouse.0095760-5.Matheos Menegakis et Steve 6-27 Menegakis 0095800-9.Dame Stella Moshona et Thomas 5-30 Lergoudakis, son époux 0096180-5.Hercules Vassiliou.5-52 0096740-6.Anastasios K.Christopoulos, Vasilios 5-82 K.Christopoulos et Nikolaos K.Christopoulos 0096760-4 Anastasios K.Christopoulos, Vasilios 5-83 K.Christopoulos et Nikolaos K.Christopoulos 0096780-2 .Anastasios K.Christopoulos.Vasilios 5-84 K.Christopoulos et Nikolaos K.Christopoulos 0096800-8 .Anastasios K.Christopoulos, Vasilios 5-85 K.Christopoulos et Nikolaos K.Christopoulos 0098190-2.Adolfo Bisecco et Dame Leonora 5-155 Mazzucco, son épouse 0098200-9.Adolfo Bisecco et Dame Leonora 5-156 Mazzucco, son épouse 0118260-9.Dlle Mary Ivanicki et John Kubiak 8-154, 155 0121150-7.Louis-Nazaire Larochelle.8-712,713 A distraire de ces lots la partie expropriée par le ministère To be withdrawn from these lots the part expropriated by the de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte Roads Department of the Province of Québec under the terms enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly of a deed registered at the County of Chambly Registry Office sous le numéro 218-412.undernumber218412.0122520-0.Summit Enterprises Inc.9-86 0122600-0.Summit Enterprises Inc.9-94 0122660-4.Summit Enterprises Inc.9-100 0122690-1.Manfred Morgenroth.9-103 0122700-8.Summit Enterprises Inc.9-104 0122970-7.Summit Enterprises Inc.9-131 0123670-2.Gin Goon.9-201 0124600-8.Michel Manganiello.9-313 0124880-6.Monarch Commerce Corp.9-341 0128960-2.Sidney R.Sumnall.Jr.Une partie du lot 9 mesurant 68.44 pieds de largeur sur A part of lot 9 measuring 68.44 feet in width by 90 feet in une profondeur de 90 pieds, bornée en front par une rue depth, bounded in front by a street (9-292), in rear by lots (9-292), en arrière par les lots 8-498 à 500, d'un côté par le 8-498 to 500, on one side by lot 9-400 and on the other side by lot 9-400 et de l'autre côté par une autre partie du lot 9.another part of lot 9.0129160-8.Sinclair Collymore Une partie du lot 9 se décrivant comme suit: Commençant à l'angle nord-est du lot 9, de là vers le sud-est le long de la limite nord-est du lot 9 sur une distance de 6,204.09 pieds, de là, vers le sud-ouest et à angle droit vers la limite nord-est du lot 9, sur une distance de 402 pieds jusqu'au point de départ.Commençant au point de départ, de là vers le sud-ouest à angle droit avec la limite nord-est du lot 9 sur une distance de 100 pieds, de là, vers le sud-est en suivant une ligne parallèle à la limite nord-est du lot 9 sur une distance de 65 pieds, de là, en direction nord-est et à angle droit avec la limite nord-est du lot 9 sur une distance de 100 pieds, de là, en direction nord-ouest en suivant une ligne parallèle à la limite nord-est du lot 9 sur une distance de 65 pieds jusqu au point de départ; contenant une superficie de 6,500 pieds carrés.Cettedite partie du lot 9 est bornée au nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest par d'autres parties dudit lot 9.A part of lot 9 described as follows : Commencing at the northeast angle of lot 9, thence southeasterly and along the northeasterly boundary of lot 9 a distance of 6,204.09 feet, thence southwesterly and at right angles to the northeasterly boundary of lot 9, a distance of 402 feet to the point of commencement.Commencing at the point of commencement, thence southwesterly and at right angles to the northeasterly boundary line of lot 9 a distance of 100 feet, thence southeasterly and parallel to the northeasterly boundary line of lot 9 a distance of 65 feet, thence northeasterly and at right angles to the northeasterly boundary of lot 9 a distance of 100 feet, thence northwesterly and parallel to the northeasterly boundary of lot 9 a distance of 65 feet to the point of commencement, containing a superficial area of 6,500 square feet.That said part of lot 9 is bounded on the northeast, southeast, southwest and northwest by other parts of said lot 9. 3844 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Folio Nom \u2014 Name Lot 0130080-5.John A.Belamisca, Jr.et Dame Carole Anne Baugh, son épouse Une partie du lot 9 se décrivant comme suit : Commençant à l'angle nord-est du lot 9.de là en direction sud-ouest le long de la limite nord-est du lot 9 sur une distance de 6.494.05 pieds, de là.en direction sud-ouest et à angle droit avec la limite nord-est du lot 9 sur une distance de 156 pieds jusqu'au point de départ.Commençant au point de départ, de là en direction sud-est en suivant une ligne parallèle à la limite nord-est du lot 9 sur une distance de 67 pieds, de là, en direction sud-ouest et à angle droit avec la limite nord-est du lot 9 sur une distance de 90 pieds, de là, en direction nord-ouest en suivant une ligne parallèle à la limite nord-est du lot 9 sur une distance de 67 pieds, de là, en direction nord-est à angle droit avec la limite nord-est du lot 9 sur une distance de 90 pieds jusqu'au point de départ ; contenant une superficie de 6,030 pieds carrés.Cettedite partie du lot 9 est bornée au nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest par d'autres parties dudit lot 9.A part of lot 9 described as follows: Commencing at the northeast angle of lot 9, thence southwesterly and along the northeasterly boundary of lot 9 a distance of 6,494.05 feet, thence southwesterly and at right angles to the northeasterly boundary of lot 9 a distance of 156 feet to the point of commencement.Commencing at the point of commencement, thence southeasterly and parallel to the northeasterly boundary of lot 9 a distance of 67 feet, thence southwesterly and at right angles to the northeasterly boundary of lot 9 a distance of 90 feet, thence northwesterly and parallel to the northeasterly boundary of lot 9 a distance of 67 feet, thence northeasterly and at right angles to the northeasterly boundary of lot 9 a distance of 90 feet to the point of commencement: containing a superficial area of 6,030 square feet.That said part of lot 9 is bounded on the northeast, southeast, southwest and northwest by other parts of the said lot 9.0151500-6.James Norman Craik et The Royal 23-791, 792.793 Trust Company, D.Clare Peterkin et James Norman Craik, ès qualité d'exécuteurs-testamentaires et de fiduciaires de la succession de / tn their capacity as testamentary executors and trustees of the estate of Dlle Marion Gertrude Peterkin À distraire de ces lots la partie vendue à la ville de Saint-Hubert aux termes d'un acte de vente enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 298552.To be withdrawn from said lots the part sold to the City of Saint-Hubert under the terms of a deed of sale registered at the County of Chambly Registry Office under number 298552.0159380-5.Manoug Akelian.38-33 0159740-0.Dlle Constadina Lambiri.38-68 0160800-9.Dame Vassiliki Marditsi et Panagio- 38-184 tis Katselis son époux, et Dame Angela Marditsi et Dimitrios Sika-ras, son époux 0195970-9.Guy Préfontaine, G.-Eugène Vallée, André Lamarre et Germain Léger 0195980-8.Steve Haas.0195990-7.Guy Préfontaine, G.-Eugène Vallée, André Lamarre et Germain Léger 0196050-9.Platon Pendelidis.0196070-7.Platon Pendelidis.0196900-5.Dame El isabeth Berkes veuve Joseph Boros 0198550-6.Ernest Yana.0202610-2.The Protestant Board of School Commissioners of St.Hubert La moitié sud-ouest du lot 50-7 mesurant 60 pieds de largeur sur une profondeur de 120 pieds, bornée en front par une rue (50-43), en profondeur par le lot 51, au sud-ouest par le lot 50-8 et de l'autre côté par le résidu dudit lot 50-7.48-27; 49-240 48-28; 49-241 48-29; 49-242 48-51 48-52 48-96 49-47-1 The southwest half of lot 50-7 measuring 50 feet in width by a depth of 120 feet, bounded in front by a street (50-43), at the rear by lot 51, on the southwest by lot 50-8 and on the other side by the remainder of said lot 50-7.The undivided quarter of lot 50-16.To withdraw the part sold to John Francis Rooney under the terms of a deed registered at the County of Chambly Registry Office under number 54466.0202780-3.Ernest Yana.Le quart indivis du lot.0202910-6.Ernest Yana.50-23 A distraire la partie vendue à John Francis Rooney aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 54466.0206810-4.Ernest Bohnet.53-3 0207040-7.Lucien Dubeau.53-26 0207510-9.Horst Tummler.53-73 0207520-8.Horst Tummler.53-74 0208080-2.Nick Demas.53-128 0208630-4.Dame Sheila Waterman, épouse 63-174 Kenneth Dummett 0209240-1.Santos Investment Corp.Une partie du lot 53-253 mesurant 22.69 pieds de largeur A part of lot 53-253 measuring 22.69 feet in width by the par toute la profondeur dudit lot, bornée en front par le chemin whole depth of said lot, bounded in front by Chambly Road, at GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3845 Folio Nom \u2014 Name Lot Chambly, en arrière par le lot 53-239, au nord-ouest par le résidu dudit lot 53-253 et au sud-est par partie du lot originaire numéro 53.the rear by lot 53-239, on the northwest by the remainder of said lot 53-253 and on the southeast by part of original lot number 53.0210070-9.Santos Investment Corp.53-351 0210080-8.Santos Investment Corp.53-352 0210090-7.Santos Investment Corp.53-353 0210360-4.Santos Investment Corp.Une partie du lot 53 mesurant 38.09 pieds en front, 157.73 pieds dans sa ligne nord-ouest et 191.83 pieds dans sa ligne sud-est, bornée en front par le chemin Chambly, en arrière par les lots 53-239 et 240, au nord-ouest par le lot 53-253 et au sud-est par une autre partie dudit lot 53.A part of lot 53 measuring 38.09 feet in front, 167.73 feet on its northwest line and 191.83 feet on its southeast line, bounded in front by Chambly Road, at the rear by lots 53-239 and 240, on the northwest by lot 53-253 and on the southeast by another part of said lot 53.0210380-2 0210390-1.0210400-8.0210410-7 0210420-6 0210430-5 0210440-4 0210450-3 0210560-9.0210580-7 0210590-6.0210600-3.0210750-6.0210760-5.0210770-4.0210780-3.0210790-2.0210800-9.0210810-8.0210820-7, 0210830-6.0210840-5.0210850-4.0210860-3.0210870-2.0210880-1.0211040-1.0211050-0.0225080-1.À distraire la partie expropriée voirie de la province de Québec aux très au bureau d'enregistrement du les numéros 328356 et 346626.Santos Investment Corp.53-371 Santos Investment Corp.53-372 Santos Investment Corp.et Joao 53-373 Fernandes Da Trindade Santos Investment Corp.63-374 Santos Investment Corp.63-375 Santos Investment Corp.53-376 Santos Investment Corp.53-377 Santos Investment Corp.53-378 Santos Investment Corp.53-389 Santos Investment Corp.53-392; 53-244-1 Santos Investment Corp.53-393; 53-244-2 Santos Investment Corp.63-394 Santos Investment Corp.53-409 Santos Investment Corp.53-410 Santos Investment Corp.53-411 Santos Investment Corp.53-412 Santos Investment Corp.53-413 Santos Investment Corp.63-414 Santos Investment Corp.53-415 Santos Investment Corp.53-416 Santos Investment Corp.63-417 Santos Investment Corp.63-418 Santos Investment Corp.53-419 Santos Investment Corp.53-420 Santos Investment Corp.63-421 Santos Investment Corp.63-422 Santos Investment Corp.53-438 Santos Investment Corp.53-439 Dame Angelina Abajo Maeso épouse 56-6 divorcée de Roland Rickenbach alias Richenbach par le ministère de la To withdraw the part expropriated by the Roads Depart- termes des actes enregis- ment of the Province of Québec under the terms of the deeds comté de Chambly sous registered at the County of Chambly Registry Office under numbers 328356 and 346626.0225090-O.Dame Angelina Abajo Maeso épouse divorcée de Roland Rickenbach alias Richenbach 56-7 À distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 328356 et 346626.To withdraw the part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec under ther terms of the deeds registered at the County of Chambly Registry Office under numbers 328356 and 346626.56-94 0226140-2.La Société Universelle de Placements Limitée 0226410-9 .Werner Zefferer.66-118 0238260-4.Michael Nicholls.64-238 0238270-3.Michael Nicholls.64-239 0240050-5.Rodrigue Piley.Ç4^18 0241280-7.Domenico Dardis.65-39 0241400-1.George Zoumberakia.65-51 0241670-9.Dame Penelope Gialeli, épouse de 65-78 John Mavroulis 0243410-8.Miltiades Costi et Dame Chrysoula Arabatsidis, son épouse Une partie du lot 65-238 contenant une superficie de 5,500 A part of lot 65-238 covering an area of 5,500 square feet, pieds carrés, bornée au nord-ouest par partie du lot 65-237.bounded on the northwest by part of lot 65-237.on the north- 3846 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Folio Nom \u2014 Name Lot au nord-est par partie du lot 65-238, au sud-est par partie east by part of lot 65-238, on the southeast by part of lot du lot 65-197 et au sud-ouest par partie du lot 65-239.65-197, and on the southwest by part of lot 65-239.0243820-8.Dlle Helen Koutsoumani.Une partie du lot 65-260 mesurant 50 pieds de largeur sur A part of lot 65-260 measuring 50 feet in width by a depth of une profondeur de 100 pieds, bornée au nord-est par partie du 100 feet, bounded on the northeast by part of lot 65-263, on the lot 65-263, au sud-est par le lot 65-259, au sud-ouest par le southeast by lot 65-259, on the southwest by lot 65-198 lot 65-198 (rue) et au nord-ouest par le résidu dudit lot 65- (street), and on the northwest by the remainder of said lot 260.65-260.0244620-1.Michael Diamantis.65-301 0244690-4.Drago Radicevic et Dame Dona Kozeli, son épouse Une partie du lot 65-304 mesurant 50 pieds de largeur sur A part of lot 65-304 measuring 50 feet in width by a depth of une profondeur de 100 pieds, bornée au nord-ouest par le lot 100 feet, bounded on the northwest by lot 65-205 (street), on 65-205 (rue), au nord-est par partie du lot 65-305, au sud-est the northeast by part of lot 65-305, on the southeast by lot par le lot 65-309 et au sud-ouest par le résidu dudit lot 65-304.65-309, and on the southwest by the remainder of said lot 65.304.0244790-2.Avgy Gougos épouse de Stefanos Goziotis Une partie du lot 65-309 mesurant 50 pieds de largeur sur A part of lot 65-309 measuring 50 feet in width by a depth of une profondeur de 110 pieds, bornée au nord-ouest par le lot 110 feet, bounded on the northwest by lot 65-3C4, on the 65-304, au nord-est par le lot 65-308, au sud-est par le lot 65- northeast by lot 65-308.on the southeast by lot 65-202 (street) 202 (rue) et au sud-ouest par le résidu dudit lot 65-309.and on the southwest by the remainder of said lot 65-309.0246930-2.Nicholas Bilas.66-78 0246940-1.Nicholas Bilas.66-79 0247610-9.Maria Mezari.66-149 0247620-8.Maria Mezari.66-150 0247840-2.Victor Di Battista.66-174 0248050-7.Salvatore Ricca.66-195 0248060-6.Salvatore Ricca.66-196 0248320-4.Raymond S.Lloyd.66-222 0248330-3.Raymond S.Lloyd.66-223 0249140-5.Dame Marie Lanese, épouse 66-303 Dominique Di Francesco 0249790-7.Andrew Paraskis.66-367 0249800-4.Dame Marie Lanese, épouse 66-368 Dominique Di Francesco 0250950-3.George Riley Nelson.66-483 0251430-5.Dlle Ruth Ford.66-531 0251440-4.Dlle Ruth Ford.66-532 0251550-0.Dlle Valérie Paul.66-543 0251730-8.SaulNadler.66-561 0251740-7.SaulNadler.66-562 0251750-6.SaulNadler.66-563 0251760-5.SaulNadler.66-564 0251770-4.SaulNadler.66-565 0251900-7.George S.Allen.66-578 0251910-6.George S.Allen.66-579 0252250-6.Dennis E.Dublin.66-313 0252260-5.Dennis E.Dublin.66-614 0252270-4.Dennis E.Dublin.66-615 0252370-2.Dennis E.Dublin.66-625 0252380-1.Dennis E.Dublin.66-626 0252390-0.Dennis E.Dublin.66-627 0252400-7.Dennis E.Dublin.66-628 0252410-6.Dennis E.Dublin.66-629 0252420-5.Dennis E.Dublin.66-630 0252430-4.Dennis E.Dublin.66-631 0252610-1.Riley G.Nelson.66-649 0252620-0.Riley G.Nelson.66-650 0252630-9.Riley G.Nelson.66-651 0252640-8.Riley G.Nelson.66-652 0252650-7.Riley G.Nelson.66-653 0252660-6.Riley G.Nelson.66-654 0252670-5.Lynden Walton.66-655 0252900-6.Dlle Valérie Paul.66-678 0258470-4.Dlle Sophia Boundri.68-49 0258600-6.Christos Surligas.68-62 0258610-5.Christos Surligas.68-63 0259090-9.Triantaffilos Porfiris.68-108 0259100-6.Triantaffilos Porfiris.68-109 0269110-5.Triantaffilos Porfiris.68-110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n° 19 3847 Folio Nom \u2014 Name Lot 0259120-4.Triantaffilos Porfiris.0259700-3.Aris Sideratos.0259720-1.Aris Sideratos et Nicolas S.Dendrinos 0261360-2.Spyros Tsagarakis.0261370-1.Spyros Tsagarakis.0261380-0.Spyros Tsagarakis.0261390-9.Spyros Tsagarakis.0261500-3.Spiros Tsinas et Paul Pantazopoulos 0261510-2.Spiros Tsinas et Paul Pantazopoulos 026153O-O.George Alexopoulos.0261640-7.Spiros Tsinas et Paul Pantazopoulos 0261650-6.Spiros Tsinas et Paul Pantazopoulos 0261660-5.Spiros Tsinas et Paul Pantazopoulos 0262140-7.SperoFurla.0262230-6.Spero Furla.0262930-1.Paul Matsos.0263700-7.James Kritsas et Gust Papageorge.0263710-6.James Kritsas et Gust Papageorge.0263720-5.James Kritsas et Gust Papageorge.0263730-4.James Kritsas et Gust Papageorge.0266800-2.Michael Zajszlyj.0266810-1.Michael Zajszlyj.0267950-4.Alkate Development Inc.0268110-4.Joseph Deckelbaum.0268120-3.Joseph Deckelbaum.0269490-9.Ignacy Kneller.0269500-5.Ignacy Kneller.0270960-8.Dame Nadine Schertenleib épouse Antoine St-Pierre 0270970-7.Dame Nadine Schertenleib épouse Antoine St-Pierre 0270980-6.Dame Nadine Schertenleib épouse Antoine St-Pierre 0270990-5.Dame Nadine Schertenleib épouse Antoine St-Pierre 0271280-0.Dame Nadine Schertenleib épouse Antoine St-Pierre 0271290-9.Dame Nadine Schertenleib épouse Antoine St-Pierre 0271300-6.Dame Nadine Schertenleib épouse Antoine St-Pierre 0271310-5.Dame Nadine Schertenleib épouse Antoine St-Pierre 0271830-2.Dame Margarita Domenge De Fernandez Del Castillo, épouse Eduardo Fernandez del Castillo 0272200-7.Dame Colette Loret, épouse Roland Hazard 0272690-9.William Marie.0272740-2.Dame Margarita Domenge De Fernandez Del Castillo, épouse Eduardo Fernandez del Castillo 0273000-0 .Dame Margarita Domenge De Fernandez Del Castillo, épouse Eduardo Fernandez del Castillo 0273480-4.Alfred Kaufman.0273690-8.Alfred Kaufman.0274610-5 .Dame Margarita Domenge De Fernandez Del Castillo, épouse Eduardo Fernandez del Castillo 0274870-5 .Dame Christina Prossopari épouse Egthimios Athanassoulis 0274880-4.Dame Maria Prossopari épouse George Couris 0274980-2.Gérard Chamberland.0274990-1.Gérard Chamberland.0275160-0.Quintino Perri.0275170-9.Quintino Perri.0276600-4.Bruno Savino.0278300-9.René Bernard.0278330-6.René Bernard.0278400-7.René Bernard.0278540-0.Hervé L.Picard.0278960-0.Arthur Rodgers.0278970-9.Arthur Rodgers.0278990-7.Henri Vaccaro.68-111 69-175 68-176 68-337 68-338 68-339 68-340 68-357 68-358 68-360 68-371 68-372 68-373 68-421 68-430 68-496 68-573 68-574 68-575 68-576 69-136 69-137 69-221 69-237 69-238 69-354 69-355 70-32 70-33 70-34 70-35 70-64 70-65 70-66 70-67 70-113 70-150 70-198 70-203 70-217\u201413 70-247 70-268 70-360 70-385 70-380 70-396 70-397 70-415 70-416 72-59 72-237 72-240 72-248 72-262 72-304 72-305 72-307 3848 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975, Vol.107, No.19 Folio Nom \u2014 Name Lot 0279030-1.Dame Alice Bouchard, 72-311 épouse Richard Richard 0279040-0.Dame Alice Bouchard, 72-312 épouse Richard Richard 0279510-2.Dame Alice Bouchard, 72-362 épouse Richard Richard 0279520-1.Dame Alice Bouchard, 72-363 épouse Richard Richard 0279820-5.Dame Alice Bouchard, 72-395 épouse Richard Richard 0279830-4.Dame Alice Bouchard, 72-396 épouse Richard Richard 0280160-3.Dame Ruth Stentzel, 72-429 veuve Hans Benecke 0280820-2.Jordanov Lubomir.72-499 0300540-2.Dame Kalliopi (alias Pappy) Ksidi, 77-22 et Peter Kossivas, son époux 0300710-1.Dame Stavroula Gikas et 77-39 Nikiforos Kavadias, son époux 0300720-0 .Dame Stavroula Gikas et 77-40 Nikiforos Kavadias, son époux 0300750-7.Dame Avelyn Gabriel et John 77-43 N.Maris, son époux 0300760-6.Dame Avelyn Gabriel et John 77-44 N.Maris, son époux 0300880-2.Aristos Kostios.77-56 0300890-1.Aristos Kostios.77-57 0300990-9.Dame Beha (Kadrije) Xheka 77-67 et Sadik Xheka, son époux 0301000-6.Dame Beha (Kadrije) Xheka 77-68 et Sadik Xheka, son époux 0301010-5.Dame Beha (Kadrije) Xheka et Sa- 77-69 dik Xheka, son époux.0301020-4.Dame Beha (Kadrije) Xheka et 77-70 Sadik Xheka, son époux.0301030-3.Dame Beha (Kadrije) Xheka et 77-71 Sadik Xheka, son époux.0301070-9.Michael Kritikos.77-75 0301280-4.Dame Niki Koutsela, épouse Dimi- 77-96 trios Papanikolaou 0301540-1.Tasos Pollatos.77-135 0301750-6.Drosos William.77-147 0301760-5.Drosos William.77-148 0302190-4.Peter Belesis.77-187 0302200-1.Peter Belesis.77-188 0302210-0.Peter Belesis.77-189 0302780-2.Dlle Ageliki Fintikis.77-247 0302790-1.Dlle Ageliki Fintikis.77-248 0321710-6.Gabriel Sanon.80-37 0321950-8.Horace Best et Dame Joan Gonzales, 80-56 son épouse / his wife 0322360-9.Herbert W.Chambers.80-99 0322370-8.Herbert W.Chambers.80-100 0322750-1 .Dame Mary Louise Hodges ex- 80-140 épouse de Allan Douglass 0322830-1.Dieudonné Thy bulle.80-148 0322840-0.Dieudonné Thy bulle.80-149 0326100-5.Vernon E.White.80-201 0320510-5.Pierre Clerie.et Dame May Sansa- 80-246 recq, son épouse 0326520-4.Rodolphe Dejean.80-247 0326530-3.Rodolphe Dejean.80-248 0326700-2.Dame Clara Rouchon veuve André 80-269 Gation 0326710-1.Dame Clara Rouchon veuve André 80-270 Gation 0346040-9.André Palascak.90-98 0346070-6.André Palascak.90-99 0346100-1 .André Palascak.90-100 0346130-8.André Palascak.90-101 0346160-5.André Palascak.90-102 0346190-2.André Palascak.90-103 0346500-2.Laszlo Csere.90-114 0346510-1.Laszlo Csere.90-115 0346540-8.Laszlo Csere.90-116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1975, 107' année, n' 19 3849 Folio Nom \u2014 Name Lot 0348590-1.Ethelbert Alves et Dame Jean Hele- 91-20 nese, son épouse 0348600-8.Ethelbert Alves et Dame Jean Hele- 91-21 nese, son épouse 0348960-6.Desmond Mahoney et Dame Sylvia 91-68 Heron veuve Harold Silvera 0349220-4.Noel Stennett.91-94 0349310-3.Trevor Cunningham.91-103 0349320-2.Trevor Cunningham.91-104 0349330-1 .Trevor Cunningham.91-105 0349410-1.Noel Stennett.91-113 0349590-0.Dlle Merlin Loney.91-131 0350520-3.Lloyd Mangaroo.91-224 0350530-2.Lloyd Mangaroo.91-225 0350540-1 .Terrance E.Wright.91-226 0350560-9.Wilfred England.91-228 0350660-7.Dennis E.Dublin.91-238 0350670-6.Dennis E.Dublin.91-239 0356260-0.Dame Jeanette Taylor, et Peter Clé- 92-191 ment, son époux 0356270-9.Dame Jeanette Taylor et Peter 92-192 Clément, son époux 0356280-8.Dame Jeanette Taylor et Peter 92-193 Clément, son époux 0357600-6.Paolo Mariani et Dame Violetta 92-316 Massazza, son épouse 0357610-5.Paolo Mariani et Dame Violetta 92-317 Massazza, son épouse 0357620-4.Paolo Mariani et Dame Violetta 92-318 Massazza, son épouse 0357630-3.Paolo Mariani et Dame Violetta 92-319 Massazza, son épouse 0357640-2.Paolo Mariani et Dame Violetta 92-320 Massazza, son épouse 0357650-1.Paolo Mariani et Dame Violetta 92-321 Massazza, son épouse 0357660-0.Paolo Mariani et Dame Violetta 92-322 Massazza, son épouse 0357670-9.Paolo Mariani et Dame Violetta 92-323 Massazza, son épouse 0358120-4.Dlle Madeleine Koulakoff.92-369 0358130-3.Dlle Madeleine Koulakoff.92-370 0361000-3.François Pelletier.93-345,346,347 0361260.3.Gaston Lévesque.93-402 À distraire les % vendus à Park Realty Corporation aux To be withdrawn the three-quarters sold to Park Realty termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du Corporation, under the terms of a deed registered in the comté de Chambly sous le numéro 203383.County of Chambly Registry Office under number 203383.0361370-0.Walter Jawornicki.93-420 X distraire les % vendus à Park Realty Corporation aux To be withdrawn the three-quarters sold to Park Realty termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du Corporation, under the terms of a deed registered in the comté de Chambly sous le numéro 203383.County of Chambly Registry Office under number 203383.0361660-4.Ernest Yana.93-479 0363230-4.George Solomon.93-764 0363240-3.George Solomon.93-765, 766, 767 0363460-7.Austin Fitz O.Ward.93-812, 813 0363470-6.Austin Fitz O.Ward.93-814,815 0363590-1.Eizens Kalnins.93-840,841 0363600-8.Eizens Kalnins.93-842, 843 0363610-7.Eizens Kalnins.93-844,845 0363620-6.Eizens Kalnins.93-846.847 0363630-5.Eizens Kalnins.93-848, 849 0363640-4 .Eizens Kalnins.93-850,851 0363650-3.Eizens Kalnins.93-852, 853 0363660-2.Eizens Kalnins.93-854, 855 0363670-1.Eizens Kalnins.93-856, 857 0363680-0.Eizens Kalnins.93-858, 859 0364930-8.The Longueuil Gardens Company 93-1087, 1088 Limited 0372800-3.Karl Lawson et Dame Dorothy Chin 94-659 son épouse Louis Dixon et Dame F.Valérie 94-560 Dixon son épouse :i.s.-,(i QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May JO, J975, Vol.107, No.J9 Folio Nom \u2014 Name Lot 0372810-2.Louis Dixon et Dame F.Valérie Dixon son épouse 0372820-1 .Louis Dixon et Dame F.Valérie Dixon,son épouse 0373180-9.Eldon Craigg.0373080-8.Austin Fitz O.Ward.0375310-0.Austin Fitz O.Ward.0375320-9.Austin Fitz O.Ward.0375640-0.Austin Fitz O.Ward.0375650-9.Ernest Yan».0391710-1.Dlle Dorothy V.Russell.0391910-7.Gwendolyn Muirhead.0392140-0.Dame Lena Buchanan Dawes.0398950-6.Austin Fitz O.Ward.0399030-6.Austin Fitz O.Ward.0399070-2.Dame Harriett Mary Jones veuve Arthur Cecil Pilley 0399080-1 .Dame Harriett Mary Jones veuve Arthur Cecil Pilley 0399090-0.Dame Harriett Mary Jones veuve Arthur Cecil Pilley 0399210-4.Dame Harriett Marv Jones veuve Arthur Cecil Pilley 0399220-3.Dame Harriett Mary Jones veuve Arthur Cecil Pilley 0399230-2.Dame Harriett Mary Jones veuve Arthur Cecil Pilley 0399270-8.Alkate Development Inc.0400120-2.Austin Fitz O.Ward.0400580-7.Guiseppe Melfi.0400710-0.Dame Margaret C.Hussey épouse Randolph Pierre 0400720-9.Dame Margaret C.Hussey épouse Randolph Pierre 0400760-5.John Alfred P.Allen.0400820-7.Dame Margaret C.Hussey épouse Randolph Pierre 0400830-6.Dame Margaret C.Hussey épouse Randolph Pierre 0400840-5.Dame Margaret C.Hussey épouse Randolph Pierre 0401170-6.John Alfred P.Allen.0401180-5.John Alfred P.Allen.0401190-4.John Alfred P.Allen.0401200-1.John Alfred P.Allen.0401700-0.Austin Fitz O.Ward.0401710-9.Austin Fitz O.Ward.0401990-7.Austin Firz O.Ward.0402500-3.Austin Fitz O.Ward.0403471-6.Park Plaza Gardens Corp.0403960-9.Austin Fitz O.Ward.0404920-1.Austin Fitz O.Ward.0405010-0.Dieter Scheurmann.0408350-7.Dame Carmela Saltera épouse Arturo DiLonardo 0408360-6.Dame Carmela Saltera épouse Arturo DiLonardo 0408830-8.Dame Marie-Louise Ouellette veuve Ferdinand Bissonnette 0409160-9.Michel Ardito.0409570-9.Filberto Moffa.0409580-8.Dame Emilia Drakopoulo épouse Sotirios Vlachos 0409650-9.Luigi Calderone.0409720-0.Fred Boswell, et Dame Hilda Boswell épouse de Charles Hense 0410160-7.Dame Marie Rose Anna Emilia Pilon veuve Thomas Beaulieu 0410630-8.Violet Mary Grannary épouse Holsey Turner, Doris Frances Grannary épouse Ernest G.Bradner, Alfred John Grannary et Robert James Grannary 0410810-6.Joseph Bachorowski.94-561, 562 94-663, 564, 565 94-619 a/to 622; 93-130 à/to 133 94-724.725 94-1065.1066:93-196, 197 94-1067; 93-198 94-1127 94-1128 98-16 98-36 98-59 99-8 99-21 99-27, 28 99-29, 30 99-31.32 99-55.56 99-57, 68 99-59, 60 99-67.68 99-243 99-341, 342 99-364, 365 99-366, 367 99-377.378, 379 99-390 99-391, 392 99-393, 394 99-464.465 99-466.467 99-468, 469.470 99-471, 472, 473 99-576 99-578 99-630 99-724, 725; 100-1291, 1292 99-936 99-1032 99-1238 99-1255, 1256 100-379, 380 100-381, 382.383 100-452.453, 454 100-509, 510, 511 100-584, 585 100-586, 687 100-599, 600, 601 100-615.616 100-709, 710.711 100-805, 806 100-836, 837 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC.10 mai 1975.107e année, n\" 19 3851 Folio Nom \u2014 Name Lot 0410870-0.Violet Mary Grannary épouse Holsey Turner, Doris Frances Grannary épouse Ernest G.Bradner, Alfred John Grannary et Robert James Grannary 0411100-1.Joseph Bachorowski.0411350-2.Joseph Bachorowski.0411390-8.Dame Sarah Viner veuve Solomon Viner 0411740-4.Werner Schmidt.0411750-3.Werner Schmidt.0411780-0.Albert Jude.100-1009 0412100-0.Henri Mercier.100-1064, 1065, 1066 0415100-7.Carlos Lopes.0415110-6.Carlos Lopes.0416270-7.Laurent Kelly.0416280-6.Laurent Kelly.0416530-4.Dinos Papastathis.0416820-9.Dame Efigenia Katsigianni épouse Angelos Maragos 0416830-8.Dame Efigenia Katsigianni épouse Angelos Maragos 0416880-3.Gregorias Panagoulias.102-267,268 0416960-3.Dame Rose Ramos et Bill Ainis, son époux 0417050-2.Dame Antonine Gervais épouse Médéric Gervais 0417350-6.James Norman Craik et The Royal Trust Company, D.Clare Peterkin et James Norman Craik, es-qualité d'exécuteurs-testamentaires et de fiduciaires de la succession de Dlle Marion Gertrude Peterkin 0418450-3.Jean-Marie Gaboury.102-570 et 646 À distraire de ces lots la partie vendue à la ville de Saint- To be withdrawn from these lots the part sold to the City of Hubert aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregis- St-Hubert under the terms of a deed registered in the County gistrement du comté de Chambly sous le numéro 271417.of Chambly Registry Office under number 271417.0418610-2.Maurice Bray.102-600, 601, 602 0418630-0.Maurice Bray.102-605,606 0418640-9.Maurice Bray.102-607,608 0419090-6.Gordon R.Lancaster.102-681.682 À distraire dudit lot 102-681 la partie vendue à Walter To be withdrawn from said lot 102-681 the part sold to Joseph Leonard aux termes d'un acte enregistré au bureau Walter Joseph Leonard, under the terms of a deed registered d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 167647.in the County of Chambly Registry Office, under number 167647.0419170-6.Gordon R.Lancaster.102-695,696 À distraire dudit lot 102-696 la partie vendue à Walter To be withdrawn from said lot 102-696 the part sold to Joseph Leonard aux termes d'un acte enregistré au bureau Walter Joseph Leonard, under the terms of a deed registered d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 167647.in the County of Chambly Registry Office, under number 167647.100-852, 853 100-884, 885 100-937, 938 100-945, 946 100-999, 1000 100-1001, 1002, 1003 101-240 101-241 102-146, 147 102-148, 149 102-200, 201 102-256, 257 102-258, 259 102-283, 284 102-307, 308, 309 102-371, 372, 373 0421920-0.Dame Georgia Rokakis, épouse Alex Essaris 0421930-9.Dame Georgia Manolopoulou et Demetrios Sideris, son époux 0422930-8.John Nicolopoulos.0422940-7.John Nicolopoulos.0424120-4.'.Stergios Pantagiutidis.0424520-5.Stela Konditsi.0424530-4.Stela Konditsi.0425220-1.Joseph Soucy, Arthur Gignac, Dame Liane Gignac épouse Maurice Gratton, Dame Ceneville Gignac, épouse J.Gérard Plante, Dame Marie Anna Dastous épouse Napoléon Page, Dame Lorette Dastous veuve Gérard Gauthier, Dame Cécile Dastous épouse Roger Lamoureux, Paul Dastous, Dame Pauline Dastous épouse Maurice Racette, Dame Gisèle Dastous épouse Normand 102-1231, 1232 102-1233, 1234 102-1438, 1439 102-1440,1441 102-1994D, 1995.102-2004.2005 102-2006, 2007 102-2181, 2182 3852 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10.1975.Vol.107.No.19 Folio Nom \u2014 Name Lot Raymond, Dame Simone Dastous, épouse Roméo David, M.Roméo Dastous, Dame Gilberte Dastous épouse de Roland Charbonneau, Dame Marie-Blanche Dastous épouse Laurier Gladu, Dame Rita Dastous épouse Rolland Racette, Paul-Emile Dastous, Lionel Dastous et Dame Thérèse Dastous épouse de Jean Hamel A distraire du lot 102-2182 la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 331275.To be withdrawn from lot 102-2182 that part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec, under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office, under number 331275.0426520-3.Fred Arthur Menzer.102-2456,2457 0426530-2.Fred Arthur Menzer 0426540-1.Patrick Barry, et Dame Rosalinda Matias, son épouse 0426550-0.Patrick Barry, et Dame Rosalinda Matias, son épouse 0426560-9.Cosmopolitan Investment Corp.0426570-8.Cosmopolitan Investment Corp.0427410-6.Effterpi Gianoulaki.0427770-3.Eirini Taraboulos, et Nissim Taraboulos 0428590-4.Dlle Faustine Poulin.0428600-1.Kurt Metzger.0428770-2.Dlle Faustine Poulin .102-2994,2995,2996 0428810-6.Marcus M idler.102-3303,3304 0428820-5.Marcus Muller.102-3005 0429850-1.Spiros Bafitis.102-3224 0429860-0.Spiros Bafitis.102-3225,3226,3227 102-2458, 2459, 2460 102-2461 102-2462, 2463 102-2464, 2465 102-2466, 2467 102-2648, 2649 102-2726, 2727 102-2953.2954, 2955 102-2956, 2957, 2958 0430060-4.Antonios Papadakis, et Maria Papadakis 0430070-3.George Koufalis.0430340-0.Frank Hackett .0430350-9.Frank Hackett 102-3268, 3269, 3270 102-3271, 3272 102-3379, 3380 102-3381, 3382, 3383 0431140-3.Gérard Mantha.102-3558,3559 0431150-2.Gérard Mantha.0432030-5 102-3560, 3561 0438900-3.James Dimis 0439000-1.James George Dimis.0439010-0.James George Dimis 0439170-2.Christos Kinis.0439180-1.Christos Kinis.0439190-0.Christos Kinis.0439200-7.Christos Kinis.0439210-6.Christos Kinis.0439220-5.Christos Kinis.0439230-4.Christos Kinis.Urban Homes Inc.102-3764-1, 102-3765-1, 102-3766-1, 102-3767-1 104-727 104-728 104-729 104-745 104-746 104-747 104-748 104-749 104-750 104-751 0439240-3.Christos Kinis.104-752 0439640-4.Thomas Kalavrouziotis.104-783 0439650-3.Thomas Kalavrouziotis.104-784 0439710-5.Thomas Kalavrouziotis.104-790 A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 331275.To be withdrawn that part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec, under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office, under number 331275.0439720-4.Thomas Kalavrouziotis.104-791 À distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 331275 et d'un autre acte enregistré sous le numéro 389074.To be withdrawn that part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec, under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office, under number 331275 and under the terms of another deed registered under number 389074.0439940-8.Arun Das Gupta.104-819 0440090-9.William Drosos.104-834 0440100-6.William Drosos.104-835 0440450-5.Michael Laskaris.104-862 0441070-0.John Malamo.104-916 0443950-1.F.Ernst Kroemer.105-211 0444820-5.Albert Le Bihan.105-302 0444930-2.Albert Le Bihan.105-313 G A ZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.10 mai 1975.107e année, n' 19 3853 Folio Nom \u2014 iVame Lot 0444940-1.Albert Le Bihan.105-314 0463670-0.Antonino Grignano.113-4,5,6 0403750-0.John Stavrakis.113-20.21 22 0463760-9.John Stravakis.113-23,24 25 0464390-4.John M.Pitsikoulis.113-151 0466310-0.Eric A.Llewellvn.113-632 633 0468000-5.Dlle Selina Elsie Campbell.113-1030,1031 0468010-4.Dlle Selina Elsie Campbell.113-1032.1033 0468360-3.Victorio De Melo Bras Bulhoes____ 113-1109.1110 0468390-4).Victorio De Melo Bras Bulhoes____ 113-1115,1116 0468630-9 Dlle Selina Elsie CampMI .113-1161 à 1164 046S650-7.Dlle Selina Elsie Campbell.113-1165, 1166 0468660-6.Dlle Selina Elsie Campbell.113-1167.1168 0469470-9.Honoré Bouthillier.113-1349 à 1352 0470140-5.Dlle Rita Frances Logan.113-1522, 1523, 1624 0470390-6.HughBaillie.113-1577,1578 0471080-2.Dame Kataryna Sondej et Stanis- 114-19,20 law Grzeszczyk son époux 0471090-1 .Dame Kataryna Sondej et Stanis- 114-21,22 law Grzeszczyk son époux 0473160-0.Pawel Gerasimow.114-460,461 0478660-4.George M.Mavridis.114-1067,1068 0475860-3.George M.Mavridis.114-1069.1070, 1071 0476390-0.Jaroslav Pryszlak.114-1207.1208.1209 0476440-3.Paul King.114-1220.12*1 0476540-0.Dame Vera Ivanova et George 114-1241,1242 Nesvadba, son époux 0476650-7.Fernand Peloquin.114-1266.1267 047666U-6.Fernand Peloquin.114-1268,1269 0476070-5.Fernand Peloquin.114-1270,1271 0477690-2.Donat Charpentier.114-1491,1492 0478510-1.Josef Rakoczy et le Shérif de 115-4 et/and 15 Montréal 0478520-0.Josef Rakoczy et le Shérif de 115-6, 6 Montréal 0478530-9.Josef Rakoczy et le Shérif de 115-7,8 Montréal 0478570-5.Josef Rakoczy et le Shérif de 115-13.14 Montréal 0478580-4.Josef Rakoczy et le Shérif de 115-16, 17 Montréal 0491150-9.Reynold Skerrett.118-194 0491190-5.Dlle Anna Kalouta.118-199 0491250-7.Dame Mary Margaret Littlejohn 118-205 épouse Robert Douris 0491490-9.Dlle Kathleen Hewitt.118-232 0493220-8.Angel Neira.118-423 0494240-5.M.Semen Kulbicky.119-219.220 0494250-4.Semen Kulbicky.119-221,222 0494260-3.Semen Kulbicky.119-223.224 0494270-2.Semen Kulbicky.119-225,226 0494280-1.Semen Kulbicky.119-227,228 0495050-7.Robert W.Giddings.119-393, 394.395 0495950-8.Dame Micheline Merle, épouse 119-588, 589, 590 Constantin L.Valceanu 0495970-6.Dame Micheline Merle, épouse 119-591, 692, 693 Constantin L.Valceanu 0497640-3.Dame Mabel A.Williams Barnes 119-956, 957.958 épouse Ernest Barnes 0498880-4.Orner Bélanger.119-1267,1268 0498890-3.Orner Bélanger.119-1269,1270 0499180-8.Orner Bélanger.119-1331.1332 0500880-0.Lawrence Roberts.120-95 0500890-9.Lawrence Roberts.120-96 0500900-6.Lawrence Roberts.120-97 0500910-5.Lawrence Roberts.120-98 0502040-9.Dame Maria Jadwiga Milkowska 120-243.244 veuve Stanislaw Gryziewicz 0502050-8.Dame Maria Jadwiga Milkowska 120-245,246 veuve Stanislw Gryziewicz 0502060-7.Dame Maria Jadwiga Milkowska 120-247, 248 veuve Stanislaw Gryziewicz 0502070-6.Dame Maria Jadwiga Milkowska 120-249,250 veuve Stanislaw Gryziewicz 3854 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10.1975.Vol.107.No.19 Folio Norn \u2014 Name Lot 120-251, 252 0502080-5.Dame Maria Jadwiga Milkowska veuve Stanislaw Gryziewicz 0502410-4.Andrew J.Walton.120-281 0502430-2.Dame Maria Jadwiga Milkowska 120-282 veuve Stanislaw Gryziewicz 0502710-7.Lawrence Roberts.120-318 0502750-3.Lawrence Roberts.120-322 0502830-3.Louis Winer.120-330 0502850-1.Louis Winer.120-331 0502870-9.Louis Winer.Une partie du lot 120-332 mesurant 50 pieds de largeur sur A part of lot 120-332 measuring 50 feet in width by a depth une profondeur de 125 pieds, bornée en front par une rue of 125 feet, bounded in front by a proposed street, at the rear proposée, en arrière par le lot 120-310, d'un côté par le lot by lot 120-310, on one side by lot 120-331 and on the other 120-331 et de l'autre côté par le résidu dudit lot 120-332.side by the remainder of said lot 120-332.0502880-8.Max Winer.Une partie du lot 120-332 mesurant 50 pieds de largeur sur une profondeur de 125 pieds, bornée en front par une rue proposée, en arrière par le lot 120-311, d'un côté par le lot 120-333 et de l'autre côté par le résidu dudit lot 120-332.A part of lot 120-332 measuring 50 feet in width by a depth of 125 feet, bounded in front by a proposed street, at the rear by lot 120-311, on one side by lot 120-333 and on the other side by said lot 120-332.0503310-5.Dlle Cislyn Spence.120-375 0503320-4.Dlle Cislyn Spence.120-376 0503330-3.Dlle Cislyn Spence.0503910-2.Dame Maria Jadwiga Milkouska veuve Stanislaw Gryziewicz 0503930-0.Dame Maria Jadwiga Milkouska veuve Stanislaw Gryziewicz 0504100-9.Dame Maria Jadwiga Milkouska veuve Stanislaw Gryziewicz 0504120-7.Dennis E.Dublin.0504140-5.Dennis E.Dublin.0504160-3.Dame Marie Jadwiga Milkouska veuve Stanislaw Gryziewicz 0504680-0.G.Henry Nusynowicz alias Nash 0539110-7.Christos Loucoirtis et Michael Loucoirtis 0539450-7.Haralambos Likourentzos 120-377 120-425 120-426 120-436 120-437 120-438 120-439 120-467 131-48 131-89 0539460-6.Haralambos Likourentzos.131-90 131-91 131-92 131-102 0539470-5.Haralambos Likourentzos.0539480-4.Haralambos Likourentzos.0539550-4.Dame Soula Lepenioti épouse Peter Barogiani 0539810-2.Kathreen Karkabassis.131-133 0541180-6.Nikolaos Tsatsaronis.131-296 À distraire la partie expropriée par la Ville de Saint-Hubert To be withdrawn that part expropriated by the City of aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement Saint-Hubert, under the terms of the deeds registered at the du comté de Chambly sous les numéros 395808 et 399-123.County of Chambly Registrv Office, under numbers 395808 and 399123.0541350-5.John Tzakas et Antonios Tzakas.131-316 0542771-1.Condor Construction Company Ltd.132-59-5 0542961-8.Compagnie Vanier Limitée.Une partie du lot 132-67 mesurant 4 pieds de largeur sur A part of lot 132-67 measuring 4 feet in width by a depth une profondeur de 164 pieds, bornée en front par une rue of 164 feet, bounded in front by a street (132-1À), on the (132-1A), au sud-ouest et au nord-est par d'autres parties dudit southwest and on the northeast by other parts of said lot lot 132-67, et en arrière au nord-ouest par le lot originaire 133 132-67, and in the rear on the northwest by original lot 133 ou ses subdivisions.La ligne sud-ouest de cette partie est parai- or its subdivisions.The southwest line of this part is parallel lèle et est à une distance de 96 pieds de la ligne de division entre to and at a distance of 96 feet from the dividing line between les lots 132-66 et 67 et la ligne nord-est est parallèle et est à une lots 132-66 and 67 and the northeast line is parallel to and at distance de 92 pieds de la ligne de division entre les lots 132-67 a distance of 92 feet from the dividing line between lots 132-67 et 68.and 68.0543180-4.Kostas Pateras et Angelo Pateras .132-102 0543420-4.Sudhir Kumar Jain.132-129 0543550-8.Gus Spanos.132-143 0543560-7.Gus Spanos.132-144 0548360-7.Ted Pallas.133-512,513 0548370-6.Ted Pallas.133-514,615,516 0554220-4.John Sinclair.134-1-216,217 0564430-9.The School Commissioners for the 134-1-240,241 Municipality of St.Hubert, in the County of Chambly GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.10mai 1975.107e année.n° 19 3855 Folio Nom \u2014 Name Lot 0555070-2.Dame Vasiliki Dukaki, épouse 134-1-316 Costantinos Papanikolaou 0584270-3.Dame Julia Annie Sweetman veuve 152-61,62 William Sydney Shelton Matthews 0584280-2.Dame Julia Annie Sweetman veuve 152-63, 64 William Sydney Shelton Matthews 0584290-1.Dame Julia Annie Sweetman veuve 152-65, 66 William Sydney Shelton Matthews 0584930-2.William Ewing.152-203,204 0584940-1.William Ewing.152-205, 206 0584950-0.William Ewing.152-207,208 0610540-7.Nikolaos Tsigakis.158-476 0610550-6.Nikolaos Tsigakis.158-477 0614330-9.Aurèle Brassard.158-1236 0614710-2.André Rioux.D'une partie du lot ou partie sud-ouest du lot 159-2 mesurant 60 pieds de largeur sur une profondeur de 16 pieds et huit dixièmes de pied dans une ligne et de huit pieds dans l'autre ligne, bornée au nord-ouest par les lots 158-1266 et 1267, au nord-est par le résidu dudit lot 159-2, au sud-est par le tot 160 ou ses subdivisions, et au sud-ouest par le lot 159-3; et d'une partie ou partie nord-est du lot 159-3 mesurant 30 pieds de largeur sur une profondeur de 18 pieds dans une ligne et 16.8 pieds dans l'autre ligne, bornée au nord-ouest par le lot 158-1265, au nord-est par le lot 159-2, au sud-est par le lot originaire 160 ou ses subdivisions et au sud-ouest par le résidu dudit lot 159-3.Of a part of, or the southwest part of lot 159-2 measuring 60 feet in width by 16 and eight tenths feet in depht on one line and eight feet in depth on the other line, bounded on the northwest by lots 158-1266 and 1267, on the northeast by the remainder of said lot 159-2, on the southeast by lot 160 or its subdivisions, and on the southwest by lot 159-3; and of a part or the northeast part of lot 159-3 measuring 30 feet in width by a depth of 18 feet on one line and of 16.8 feet on the other line, bounded on the northwest by lot 158-1265, on the northeast by lot 159-2, on the southeast by original lot 160 or its subdivisions and on the southwest by the remainder of said lot 159-3.0633427-0.Eli Brown Realties Inc.164-60 0641013-8.William Henry Taylor.166-6,7,8 0641014-6.Dame Rhoda Gore épouse Joseph 166-9, 10 Steele 0642240-6.William J.Fox.166-166, 167 0662030-6.James Viris et Dame Angela 171-707,708 Kaliavas son épouse, et Peter Makos 0663140-2.Christos Papoutsis.171-936,837 0664880-2.Giovanni, Michèle et Mario 171-1209,1210 Giambagno 0664890-1.Giovanni, Michèle et Mario Giam- 171-1211, 1212 bagno 0668300-7.Armando Del Papa.172-87 0668310-6.Armando Del Papa.172-88 0668320-5.Mario Giaccio.172-89 0668330-4.Mario Giaccio.172-90 0668620-8.Panagiotis et Georges Katsaros.171-112 0668710-7.Reuben A.Lynch.172-122 0669020-0.Reuben A.Lynch.172-151 0669030-9.Reuben A.Lynch.172-152 0669100-O .Georgios Souchleris.172-160:173-76 0669101-8 .Georgios Souchleris.172-161 ; 173-75 0669620-7.Dame Althea Gibson épouse Vere 172-202:173-22 Hamilton Belle 0669660-3.Emanuel Manios.172-206;173-18 0671310-1.The Protestant School Commis- 172-366; 173-641 sioners of Pinehurst and East Greenfield 067132O-O.The Protestant School Commis- 172-367; 173-642 6ioners of Pinehurst and East Greenfield 0671330-9.The Protestant School Commis- 172-368; 173-643 sioners of Pinehurst and East Greenfield 0671340-8.The Protestant School Municipality 172-369:173-645 of Pinehurst and East Greenfield 0671740-9.Dame Althea Gibson épouse Vere 173-114 Hamilton Belle 0673840-5.George Mastoropoulos.17?\"\"?ÔS 0674890-9.Benito Di Tommasso et Dame 1 < 3-430 Germaine St-Pierre veuve Louis Grenon 0674900-6.Benito Di Tommasso et Dame 173-431 Germaine St-Pierre veuve Louis Grenon 3856 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10.1975.Vol.107.No.19 Folio Nom \u2014 Name Lot 173-486 and a part of lot 173-486 measuring said part 26 feet in width bv a depth of 100 feet, being bounded in front by Nantel Street, at the rear by lot 173-390, on the southwest side bv lot 173-486 and on the northeast side by the remainder of said lot 173-485.0674910-5.Benito Di Tommasso et Dame 173-432 Germaine St-Pierre veuve Louis Grenon 0675040-0.Benito Di Tommasso et Dame 173-445 Germaine St-Pierre veuve Louis Grenon 0675050-9.Benito Di Tommasso et Dame 173-446 Germaine St-Pierre veuve Louis Grenon 0675060-8.Benito Di Tommasso et Dame 173-447 Germaine St-Pierre veuve Louis Grenon 0075600-3.Konstandinos Rallis.173-486 et une partie du lot 173-485 mesurant cettedite partie 25 pieds de largeur sur une profondeur de 100 pieds, est bornée en front par la rue Nantel, en arrière par le lot 173-390.du côté sud-ouest par le lot 173-486 et du côté nord-est par le résidu dudit lot 173-485.0676190-2.Rosaire Levasseur.173-552 0670200-9.Rosaire Levasseur.173-553 0676210-8.Rosaire Levasseur.173-554 0676320-5.René Nantel.173-566 0676650-5.John Edward Weldrick.173-594 0676710-7.The Protestant School Municipality 173-644 of Pinehurst and East Greenfield 0682821-4.George A.Nicolaidis.174-562 0682822-2.George A.Nicolaidis.174-563 0682823-0.George A.Nicolaidis.174-564 0682827-1.Dame Angela Paspatis épouse Peter 174-568 Makris 0682828-9.Peter Maoris.174-569 0682924-6.Dimitrios Soumalas et Dame Perse- 174-676 foni Pashos, son épouse 0082925-3.Dimitrios Soumalas et Dame Perse- 174-677 foni Pashos, son épouse.0682926-1.Dimitrios Soumalas et Dame Perse- 174-678 foni Pashos, son épouse 0682927-9.Dimitrios Soumalas et Dame Perse- 174-679 foni Pafhos.son épouse 0682928-7.Dimitrios Soumalas et Dame Perse- 174-680 foni Pashos, son épouse 0682929-5.Dimitrios Soumalas et Dame Perse- 174-681 foni Pashos, son épouse 0682930-3.Dimitrios Soumalas et Dame Perse- 174-682 foni Pashos, son épouse 0682931-1.Dimitrios Soumalas et Dame Perse- 174-683 foni Pashos, son épouse 0682032-9.Dimitrios Soumalas et Dame Perse- 174-684 foni Pashos, son épouse 0682933-7.Dimitrios Soumalas et Dame Perse- 174-686 foni Pashos, son épouse 0683450-1.Alain Depagne.175-512 0683460-0.Alain Depagne.175-513 0683480-8.Alain Depagne.175-514 0683640-9.Alain Depagne.175-517 0683560-7.Alain Depagne.175-518 0684360-1.Alain Depagne.175-564 0695400-2.Guiseppe Ottoni.177-140 0697110-6.Miss Caliope Cansouridou.177-302 0697120-4.Miss Caliope Cansouridou.177-303 0697130-3.Elie Papadopoulos.177-304 0697630-2.Dame Susan Fasolakis, épouse Leo 177-390 Denato 0697730-0.Alfa Construction Corp.177-401 0697740-9.Alfa Construction Corp.177-402 0697760-7.Alfa Construction Corp.177-403 0697770-6.Alfa Construction Corp.177-404 0697780-5.Alfa Construction Corp.177-405 0697790-4.Alfa Construction Corp.177-406 0697800-1.Alfa Construction Corp.177-407 0697810-0.Alfa Construction Corp.177-408 0697820-9.Alfa Construction Corp.177-409 0697830-8.Alfa Construction Corp.177-410 0697840-7.Alfa Construction Corp.177-411 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.10mai 1975.107e année, n' 19 3857 Folio Nom \u2014 Xame Lot 0697850-6.Alfa Construction Corp.177-412 0697880-3.Alfa Construction Corp.177-415 0897920-7.Alfa Construction Corp.177-419 0697990-0.Alfa Construction Corp.177-427 0698000-7.Alfa Construction Corp.177-428 0698010-6.Alfa Construction Corp.177-429 0698020-5.Alfa Construction Corp.177-430 0698030-4.Alfa Construction Corp.0698040-3.Alfa Construction Corp.0698860-4.Elie Papadopoulos.0698870-3.Elie Papadopoulos.0765950-1.Protestant Board of School Commissioners of Pinehurst and East Greenfield 0765980-8.Protestant Board of School Commissioners of Pinehurst and East Greenfield 0766990-7.Protestant Board of School Commissioners of Pinehurst and East Greenfield 0766000-1.Protestant Board of School Commissioners of Pinehurst and East Greenfield À distraire de ces lots la partie expropriée par le ministère To withdraw from these lots the part expropriated bv the de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte Roads Department of the Province of Québec under the terms enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly of a deed registered at the County of Chambly Registry Office sous le numéro 288235.under number 288235.177-431 177-432 177-514 177-515 187-1755, 1756 187-1762, 1763, 1764 187-1765, 1766 187-1767 à/to 1769 0767370-0.Protestant Board of School Commissioners of Pinehurst East Greenfield 0767380-9.Protestant Board of School Commissioners of Pinehurst and East Greenfield 0767400-5.Protestant Board of School Commissioners of Pinehurst and East Greenfield 0767430-2.Protestant Board of School Commissioners of Pinehurst and East Greenfield 0767440-1.Protestant Board of School Commissioners of Pinehurst and East Greenfield À distraire de ces lots la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 288235.187-2041 à/to 2043 187-2044, 2045 187-2046, 2047 187-2053 à/to 2055 187-2056 à/to 2068 To withdraw from these lots the part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec under the terms of u deed registered at the County of Chambly Registry Office under number 288235.0774450-1 0780640-9 0782350 3 0782400-6 0782410-5 0783650-5 078378O-O 0783830-3 0783840-2 0783930-1 0783990-5 0784000-: 0784440-0 0785380-7 0785390-6 0785780-s .Crawford Benjamin Lindsay et Dame Grace Lindsay, épouse Pierre Rainville .Dlle Ruby Allan.Dlle Cynthia King.Dlle Sephlyn Douglas.Dlle Sephlyn Douglas.Nicholas Snaith.Dlle Cynthia King.Dlle Sephlyn Douglas.Dlle Sephlyn Douglas.Emilio Francescucci.Dlle Leceeta Reece, et Barrington E.Burgher 2.Dlle Leceeta Reece, et Barrington E.Burgher .Messrs R.Douris et R.Skerrett.Dame Tillie Gruchestka veuve Stefan Yaskow alias Yasky, et Joseph, Léo, Maurice, Stella, et Helen Yasky .Dame Tillie Gruchestka veuve Stefan Yaskow atias Yasky, et Joseph.Leo, Maurice, Stella et Helen Yasky .Provident Development Corporation 188-217 189-1360 189-1741 189-1756 189-1758 189-2013 189-2041 189-2056, 189-2058 189-2080 189-2090, 1361 à/to 1743 , 1757 1759 2014 à/fo 2043 2057 , 2069 2081 2091 189-2092, 2093 189-2197 àt/to 2202 189-2406, 2407 189-2408, 2409 189-2472 à/fo 2474 3858 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10, 1975.Vol.107.No.19 Folio Nom \u2014 Name Lot 0793110-8.Dame Maria Jadwiga Milkowska 192-261,262 épouse Stanislaw Gryziewicz 0793120-7.Dame Maria Jadwiga Milkowska 192-263, 264 épouse Stanislaw Gryziewicz 0793130-6.Dame Maria Jadwiga Milkowska 192-265,266 épouse Stanislaw Gryziewicz 0793140-5.Dame Maria Jadwiga Milkowska 192-267, 268 épouse Stanislaw Gryziewicz 0793150-4.Dame Maria Jadwiga Milkowska 192-269,270,271 épouse Stanislaw Gryziewicz 0793160-3.Dame Maria Jadwiga Milkowska 192-272, 273, 274 épouse Stanislaw Gryziewicz 0793210-6.Dlle Marie-Lucie Jetée.192-285.286 0793270-0.Leo Margaritis.192-297 a/to 299 À distraire de ces lots la partie expropriée par le ministère To withdraw from these lots the part expropriated by the de la voirie de la province de Québec aux termes des actes Roads Department of the Province of Québec under the terms enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly of the deeds registered at the County of Chambly Registry sous les numéros 288235 et 418085.Office under numbers 288235 and 418085.0793280-9.Leo Margaritis.192-325 à/io 327 A distraire de ces lots la partie expropriée par le ministère To withdraw the part expropriated by the Roads Depart-de la voirie de la province de Québec aux termes des actes ment of the Province of Québec under the terms of the deeds enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly registered at the County of Chambly Registry Office under sous les numéros 265925 et 418085.numbers 265925 and 418085.0793600-8.François St-Onge.0794400-2.Dame Sophia Ikonomea épouse Serafim Politis 0794410-1.Elie Papadopoulos.0794420-0.Elie Papadopoulos.0794430-9.Elie Papadopoulos.0794440-8.Elie Papadopoulos.0794450-7.Elie Papadopoulos.0794460-6.Elie Papadopoulos.0794470-5.Elie Papadopoulos.0794480-4.Elie Papadopoulos.0794490-3.Elie Papadopoulos.0794500-9.Dame Penelope Amvoulou épouse Evangelos Kyriazis 0794960-5.François St-Onge.0795280-7.Dame Maria Jadwiga Milkowska épouse Stanislaw Gryziewicz 0795290-6.Dame Maria Jadwiga Milkowska épouse Stanislaw Gryziewicz 0795300-3.Dame Maria Jadwiga Milkowska épouse Stanislaw Gryziewicz 0795310-2.Dame Maria Jadwiga Milkowska épouse Stanislaw Gryziewicz 0795320-1.Dame Maria Jadwiga Milkowska épouse Stanislaw Gryziewicz 0795980-2.Joseph Torchia.0795990-1.Joseph Torchia.0797030-4.Peter Greenberg.0797330-8.Pasquale Rocco.0799430-4.Santos Investment Corp.0799436-1.Dr.Hu Shih Chang et Mrs Chau Miu Kwan 0799438-7.Santos Investment Corp.0799439-5.Dr.Hu Shih Chang et Mrs Chau Miu Kwan 0799440-3.Dr.Hu Shih Chang et Mrs Chau Miu Kwan 0799441-1.Santos Investment Corp.0799443-7.Santos Investment Corp.0799444-5.Santos Investment Corp.0799449-4.Santos Investment Corp.0799451-0.Santos Investment Corp.0799452-8.Santos Investment Corp.0799454-4.Santos Investment Corp.0799455-1 .Santos Investment Corp.0799458-5.Santos Investment Corp.0799510-3.Dr.Hu Shih Chang et Mrs Chau Miu Kwan 192-387 192-550, 551 192-552, 553,554 192-555, 556 192-557, 558 192-559, 560 192-561, 562 192-563.564 192-565.566 192-567, 568 192-569 192-570 a/to 573 192-687 192-762, 763 192-764.765 192-766, 767 192-768 à/to 770 192-771 alio 773 192-905.906 192-907, 908 192-1158, 1159 192-1229, 1230 194-93 194-104;195-94 194-101 194-102;195-92 194-103;195-93 194-105; 194-107; 194-108; 194-113; 194-115; 194-116; 194-118; 194-119; 194-122; 195-90 195-128 195-126 195-125 195-120 195-118 195-117 195-115 195-114 195-131 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC.10 mai 1975.107e année.n° 19 3859 Folio Nom \u2014 Name Lot 195-91 195-95 195-96 195-97 195-148 195-149 0799511-1.Dr.Hu Shih Chang et Mrs Chau Miu Kv.0799512-9.Dr.Hu Shih Chang et Mrs Chau Miu Kwan 0799513-7.Dr.Hu Shih Chang et Mrs Chau Miu Kwan 0799514-5.Santos Investment Corp.0799530-1 .Santos Investment Corp.I95-Ï29 0799531-9.Santos Investment Corp.195-130 0799547-5.Santos Investment Corp.0799548-3.Santos Investment Corp.0801464-9.Antonio Jose Mande*.Une partie du lot 194 mesurant 56.2 pieds de largeur sur une A part of lot 194 measuring 56.2 feet in width by a depth profondeur de 90 pieds, bornée en front par une rue (194-78), of 90 feel, bounded in front bv a street (194-78).on one side d'un côté par le lot 194-121.en arrière par partie du lot 194- by lot 194-121, in rear by part of lot 194-124 and on the other 124 et de l'autre côté par partie dudit lot 194.side by part of said lot 194.0801465-6.Jose Da Rocha Alves.Une partie du lot 194 mesurant 55 pieds de largeur sur une profondeur de 118.5 pieds dans sa ligne sud-ouest et 118.35 pieds dans sa ligne nord-est, bornée en front par une rue proposée (ptie 194), en arrière par ptie du lot 193 et des deux côtés par d'autres parties dudit lot 194.La ligne sud-ouest est à une distance de 871.14 pieds de la rue Grande-Allée.0801466-4.Joao Augusto F.Carias .Une partie du lot 194 mesurant 55 pieds de largeur sur une profondeur de 118.05 pieds dans sa ligne sud-ouest et 118 pieds dans sa ligne nord-est, bornée en front par une rue proposée (ptie 194), en arrière par une partie du lot 193, des deux côtés par d'autres parties dudit lot 194.La ligne sud-ouest est & une distance de 1036.14 pieds de la rue Grande-Allée.0801467-2.Jose Vicente.Une partie du lot 194 mesurant 56.2 pieds de largeur sur une profondeur de 90 pieds, bornée en front par une rue (194-78).d'un côté par le lot 194-122, en arrière par partie du lot 194-123 et par partie du lot 194-124 et de l'autre côté par une autre partie dudit lot 194.A part of lot 194 measuring 55 feet in width by a depth of 118.5 feet on its southwest line and 118.35 feet on its northeast line, bounded in front by a proposed street (Pt.194), in rear by part of lot 193 and on both sides by other parts of said lot 194.The southwest line is located at a distance of 871.14 feet from Grande-Allée Street.A part of lot 194 measuring 55 feet in width by a depth of 118.05 feet on its southwest line and 118 feet on its northeast line, bounded in front by a proposed street (Pt.194), in rear by a part of lot 193, on both sides by other parts of said lot 194.The southwest line is located at a distance of 1.306.14 feet from Grande-Allée Street.A part of lot 194 measuring 56.2 feet in width by a depth of 90 feet, bounded in front by a street (194-78), on one side by lot 194-122, in rear by part of lot 194-123 and by part of lot 194-124 and on the other side by another part of said lot 194.0801474-8.Santos Investment Corp.0801476-3.Abel De Trindale Vaz .Une partie du lot 194 mesurant 55 pieds de largeur sur une profondeur de 107.7 pieds dans sa ligne nord-est et 108.16 pieds dans sa ligne sud-ouest, bornée en front au nord-ouest par partie du lot 193 et de tous les autres côtés par d'autres parties dudit lot 194.Cet emplacement est situé a 2.366.14 pieds de la rue Grande-Allée.194-100 A part of lot 194 measuring 55 feet in width by a depth of 107.7 feet on its northeast line and 108.16 feet on its southwest line, bounded in front on the northwest by part of lot 193 and on all other sides by other parts of said lot 194.This emplacement is located at a distance of 2,366.14 feet from Grande-Allée Street.0801478-9.Alfreda Simoes.Une partie du lot 194 mesurant 60 pieds de largeur sur une profondeur de 105.76 pieds dans sa ligne sud-ouest et 105.98 pieds dans sa ligne nord-est, bornée au nord-ouest par partie du lot 193 et de tous les autres côtés par d'autres parties dudit lot 194.La ligne sud-ouest est située à 1,691.14 pieds de la rue Grande-Allée.0801479-7.Jorge Manuel de Jésus.Une partie du lot 194 mesurant 55 pieds de largeur sur une profondeur de 107.17 pieds, bornée au sud-ouest par partie du lot 194 appartenant à Jose E.G.De Jésus, au nord-ouest par partie du lot 193, au sud-est et au nord-est par d'autres parties dudit lot 194, La ligne sud-ouest est à une distance de 2,081.14 pieds de la rue Grande-Allée.0801481-3.Antonio Ferreira Amaro Une partie du lot 194 mesurant 55 pieds de largeur sur une profondeur de 107.25 pieds, bornée au nord-ouest par une partie du lot 193, d'un côté au nord-est par le lot 194-100, en front par une rue (194-77) et du côté sud-ouest par une autre partie dudit lot 194.La ligne sud-ouest est & une distance de 2,411.14 pieds de la Grande-Allée.A part of lot 194 measuring 60 feet in width by a depth of 105.76 feet on its southwest line and 105.98 feet on its northeast line, bounded on the northwest by part of lot 193 and on all other sides by other parts of said lot 194.The southwest line is located at a distance of 1,691.14 feet from Grande-Allée Street.A part of lot 194 measuring 55 feet in width by a depth of 107.17 feet, bounded on the southwest by part of lot 194 belonging to Jose E.G.De Jesus, on the northwest by part of lot 193.on the southeast and on the northeast by other parts of said lot 194.The southwest line is located at a distance of 2.081.14 feet from Grande-Allée Street.A part of lot 194 measuring 55 feet in width by a depth of 107.25 feet, bounded on the northwest by a part of lot 193.on one side on the northeast by lot 194-100.in front by a street (194-77) and on the southwest side by another part of said lot 194.The southwest line is located at a distance of 2,411.14 feet from Grande-Allée. 3860 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10.1975.Vol.107.No.19 Folio Nom \u2014 Name Lot 0801482-1.Jose Eduardo G.De Jesus.Une partie du lot 194 mesurant 55 pieds de largeur sur une profondeur de 107.17 pieds dans sa ligne nord-est et 106.97 pieds dans sa ligne sud-ouest, bornée au nord-ouest par une partie du lot 193, au nord-est par la partie du lot 194 appartenant à Jorge Manuel De Jésus, et des autres côtés par d'autres parties dudit lot 194.La ligne sud-ouest de cette partie est située à 2,026.14 pieds de la Grande-Allée.A part of lot 194 measuring 55 feet in width by a depth of 107.17 feet on its northeast line and 106.97 feet on its southwest line, bounded on the northwest by a part of lot 193, on the northeast by that part of lot 194 belonging to Jorge Manuel De Jesus, and on the other sides by other parts of said lot 194.The southwest line of this part is located at a distance of 2,026.14 feet from Grande-Allée.0801490-4.A.Dos Santos Batista Andarde____ Une partie du lot 194 mesurant 110 pieds de largeur sur une profondeur de 105.98 pieds dans sa ligne sud-ouest et de 106.38 dans sa ligne nord-est, bornée au nord-ouest par une partie du lot 193 et de tous les autres côtés par d'autres parties dudit lot 194.La ligne sud-ouest de cette partie est située à 1,861.14 pieds de la Grande-Allée.A part of lot 194 measuring 110 feet in width by a depth of 105.98 feet on its southwest line and of 106.38 feet on its northeast line, bounded on the northwest by a part of lot 193 and on all other sides by other parts of said lot 194.The southwest line of this part is located at a distance of 1,851.14 feet from Grande-Allée.Raymond Brassard.Une partie du lot 160 bornée comme suit: en front par la rue Redmond (160-80), d'un côté par le lot 160-81, en arrière par une partie des lots 159-186 et 187, et de l'autre côté par le lot 160-79.Morris Pollack.Une partie du lot 147, de figure irrégulière, bornée vers le sud-est par une partie du lot 145-281, les lots 145-277 à 280, et une partie du lot 145-242, vers le sud-ouest par une partie du lot 147-189, vers le nord-ouest par les lots 147-195 à 198 et une partie du lot 147-194, mesurant 289.61 pieds dans sa ligne sud-est, 40.62 pieds dans sa ligne sud-ouest et 275.4 pieds dans sa ligne nord-ouest mesuré le long d'un arc de cercle engendré par un rayon de 1,028.38 pieds, contenant une superficie de 3,621 pieds carrés.A part of lot 160 bounded as follows: in front by Redmond Street (160-80) on one side by lot 160-81, at the rear by a part of lots 159-186 and 187, and on the other side by lot 160-79.A part of lot 147, of irregular configuration, bounded towards the southeast by a part of lot 145-281, lots 145-277 to 280, and a part of lot 145-242, towards the southwest by a part of lot 147-189, towards the northwest by lots 147-195 to 198 and a part of lot 147-194, measuring 289.61 feet on its southeast line, 40.62 feet on its southwest line and 275.4 feet on its northwest line measured along the arc of a circle having a radius of 1,028.38 feet, covering an area of 3,621 square feet.0908627-3.Jovan Adamovic.0908628-1.Jovan Adamovic.0908791-7.Gaston Labelle.0909508-4.Les Immeubles Roluc Inc.À distraire de ces lots les lots 199-177-1 et 199-178-1.212-454, 455 Par.St-Antoine-de-Longueuil.212-452, 453 Par.St-Antoine-de-Longueuil .212-1053 Par.St-Antoine-de-Longueuil .199-177, 178 Par.St-Antoine-de-Longueuil.To be withdrawn from these lots 199-177-1 and 199-178-1.0930301-7.Montreal Suburban Investment Co.Ltd.et Emgo Realty Corp.0930517-8.Harold Block.0954960-1.Christophe Antoine Geoffrion et Dame Renée Geoffrion épouse Henri Vautelet, ès qualité de fiduciaires nommés dans un acte de donation à eux consenti par Aimé Geoffrion et Dame Rita Thibau-deau, son épouse, passé devant Me F.Samuel Mackay, notaire, le 23 février 1942 / in their capacity ae trustees appointed by a deed of gift inter vivos granted to them by Aimé Geoffrion and Mrs.Rita Thibaudeau.his wife, and executed before Me F.Samuel Mackay, rto-tary, on February 23, 191,2.Une partie du lot 236-46-2, paroisse de St-Antoine-de-Lon-geuil, mesurant 7.5 pieds de largeur sur une profondeur de 200 pieds, bornée a un bout par une partie du lot 236-46-1, à l'autre bout par une partie dudit lot 236-46-2, d'un côté par une partie dudit lot 236-46-2 vendue à Ernest Board, et de l'autre côté par les lots 236-51 à 59.208-936 Par.St-Antoine-de-Longueuil 208-892 Par.St-Antoine-de-Longueuil A part of lot 236-46-2, Parish of St-Antoine-de-Longueuil, measuring 7.5 feet in width by a depth of 200 feet, bounded at one end by a part of lot 236-46-1, at the other end by a part of said lot 236-46-2, on one side by a part of said lot 236-46-2 sold to Ernest Board, and on the other side by lots 236-51 to 59.0958701-5.Les Immeubles Roluc Inc.199-148, 149 À distraire de ces lots la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 289134 et 336551.Cesdits lots sont de la paroisse de St-Antoine-de-Longueuil.To be withdrawn from these lots that part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec, under the terms of the deeds registered in the County of Chambly Registry Office, under numbers 289134 and 336551.Said lots are situated in the Parish of St-Antoine-de-Longueuil. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 10mai 1975, 107eannée./i° 19 3861 0958703-1.Les Immeubles Roluc Inc.199-146, 147 Par.St-Antoine-de-Longueuil À distraire de ces lots la partie expropriée par le ministère To be withdrawn from these lots that part expropriated de la voirie de la province de Québec aux termes des actes by the Roads Department of the Province of Québec, under enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly the terms of the deeds registered in the County of Chambly sous les numéros 289134 et 336651, Registry Office, under numbers 289134 and 336651.199-131 Par.St-Antoine-de-Longueuil 209-305, 306 Par.St-Antoine-de-Longueuil 0958719-7.Les Immeubles Roluc Inc.0969901-8.Istvan Nagy.À distraire de ces lots la partie expropriée par la cité de To be withdrawn from these lots that part expropriated by LaSèche aux termes de l'acte enregistré au bureau d'enregis- the City of Laftèche under the terms of the deed registered trement du comté de Chambly sous le numéro 277465.in the County of Chambly Registry Office under number 277465.0979201-1.Otto Derksen.0980315-6.Frank Straub, et Cité de Laflèche.0998726-4.Dame Livia Mande! et George Vidor, son époux 0998857-7.Pierre Villeneuve Inc.0998859-3.Pierre Villeneuve Inc.De Grand Pré Construction Ltd.et William Yates De Grand Pré Construction Ltd.et Eugène Patenaude 0400760-6.John Alfred P.Allen.0960258-2.Montreal Suburban Investment Co.Ltd.et Emgo Realty Corp.Une partie du lot 208, paroisse St-Antoine-de-Longueuil, bornée au nord-est par une partie du lot 208-509, au sud-est par une partie du lot 208-839, au sud-ouest par le lot 208-831 et au nord-ouest par une partie du lot 208-477 et le lot 208-478, mesurant seize pieds dans ses lignes nord-est et sud-ouest et 41.4 pieds dans ses lignes sud-est et nord-ouest, contenant une superficie de 662 pieds carrés.208-884; 209-874 Par.St-Antoine-de-Longueuil 212-1273, 1274 Par.St-Antoine-de-Longueuil 212-1196.1197 Par.St-Antoine-de-Longueuil.212-621 à//o 623 Par.St-Antoine-de-Longueuil.212-619, 620 Par.St-Antoine-de-Longueuil 212-1298 Par.St-Antoine-de-Longueuil 212-1305 Par.St-Antoine-de-Longueuil 99-374 à/to 376 Par.St-Hubert.A part of lot 208 Parish of St-Antoine-de-Longueuil, bounded on the northeast by a part of lot 208-509, on the southeast by a part of lot 208-839, on the southwest by lot 208-831 and on the northwest by a part of lot 208-477 and lot 208-478, measuring sixteen feet on its northeast and southwest lines and 41.4 feet on its southeast and northwest lines, covering an area of 662 square feet.La vente des immeubles décrits dans la deuxième section sera définitive et sans droit de retrait conformément aux dispositions spéciales de la charte de la ville.Lesdits immeubles étant des lots vacants dont l'évaluation municipale ne dépasse pas mille dollars ($1,000).Permission a été accordée par la Commission municipale de Québec en date du 17 février 1975 pour autoriser une enumeration abrégée des numéros cadastraux.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.Tous les lots ci-dessus décrits font partie du cadastre officiel de la paroisse de St-Hubert, sauf dans les cas contrairement indiqués.Tous les lots sont sujets aux servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes ainsi qu'à toutes homologations inhérentes auxdits immeubles.Toutes les mesures ci-dessus nommées sont en mesures anglaises et plus ou moins, sauf dans les cas contrairement indiqués.Donné sous mon seing, en la ville de Saint-Hubert, ce 15e jour d'avril 1975.L'officier en charge de la vente, 60693-18-2-o Bernard Houle, greffier.Pursuant to the special provisions of the City charter, the sale of the immoveables described in the second section of the list, will be final and without any right of redemption, the said immoveables being vacant lots not exceeding one thousand dollars (81,000) in municipal valuation.Permission has been granted by the Municipal Commission of Québec, on February the 17th, 1975, in order to authorize an abridged enumeration of the cadastral numbers.Full purchase price shall be paid immediately for each of these immoveables.All the above-described lots are part of the official cadastre for the Parish of Saint-Hubert, except where otherwise indicated.All lots are subject to active or passive, apparent or nonapparent servitudes as well as to all homologations inherent to said immoveables.All measurements given hereinabove are in English measure and more or less, except where otherwise indicated.Given under my hand, in St-Hubert, on this 15th day of April, 1975.Bernard Houle, City clerk, 60693-18-2-o Officer in charge of the sale.Folio Nom \u2014 Name Lot 3862 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10.1975.Vol.107.No.19 Ville de Rosemère Avis public est par les présentes dcnné par le soussigné greffier de la susdite municipalité que: Les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique au poste Police-Incendie, 428, Grande-Côte, Rosemère, ccmté de Terrebonne, Que., MERCREDI, le VINGT-HUITIÈME jcur de MAI, 1975, à DIX heures du matin (heure avancée de l'est), pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts, plus les frais subséquemment encourus à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.La Commission municipale du Québec par décision en date du 22 avril 1975 a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles sous l'autorité de la Loi des cités et villes, article 550 (S.R.Q.1974, chapitre 193).Town of Rosemère Public notice is hereby given by the undersigned clerk of the aforesaid Municipality that: The properties hereinafter described will be sold by public auction at the Police and Fire Station, 428 Grande-Côte, Rosemère, County of Terrebonne, Que., on WEDNESDAY, the TWENTY-EIGHTH day of MAY, 1975, at TEN o'clock in the forenoon (Day-lignt Saving Time), to satisfy the payment of the municipal and school taxes, with interest, plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale.The Québec Municipal Commission by a decision dated April 22, 1975.has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immoveables under the authority of article 550 of the Cities and Towns Act (R.S.Q.1974.Chapter 193).Taxes Taxes Propriétaires No de cadastre mun.scol.Owneri Cadastral No.Munie.School taxes taxes Dorais, Michel.72-17.* 613.17 3 33.61 Ryshpan, Mrs.Virginia.45-15,-14, P45-16,-17.-18, P45 .573.92 625.42 (Mutation 322586-12/66) Dupuis, Aurel.P45-98, 45-97.1,783.09 207.97 (Mutation 396632-1/72) Billet.Suce.Achille.63-27.1,365.50 3.190.20 Lessard, J.P.42-39,-40.$ 1,090.42 S 457.60 Spathodia Land Corp.235-18,-15-2.687.78 .02 Spathodia Land Corp.235-17-2 .776.45 .03 Gagnon, Mme Marielle.48-66.1,168.19 271.73 Spathodia Land Corp.235-16,-17-1.706.65 .03 Pilon, Mme Jacqueline.44-13 .264.56 8.69 Roberge, J.A.237-203.486.88 15.33 Wylie, Mrs.Fave.41-113,-114,36-40,36-41.1,011.05 486.98 Watkins.Mrs.Vina.35-17,-18.59.91 71.81 Poirier, George.33-37.524.73 11.64 Coulombe, D., Paquette, N.31-6 .450.25 699.89 Coulombe, D.Paquette, N.30-184 .9.99 50.44 Billet, Suce.Achille.37-43, P37-42.1,132.29 2,762.57 (Mutation 217900-7/57) Siodmok, Mrs.Ingrid.242-39.-40.1,853.54 Dawson, Mrs.Shirley.253-21,-22.1,120.53 669.79 Pilon, Mme Hélène.P242 (Tel que décrit à la mutation no 383404- 2,734.93 482.98 4/71).Leslie, Gordon.35-3-5,-3-6,-24,-26, P35-20.982.30 765.49 (Mutation 279144-7/63) Savard, Roland.241-272.714.67 137.27 Millette, Charles.35-5,-6,-7,-8.1,145.74 295.97 St-Amour, Laurier.33-11.655.86 Rolland, Mme Nicole.29-11,-10.802.65 17.34 Badger, C.K.30-175-2,-176.1.431.82 1,283.78 Zeelnv.Ltd.30-289 .468.33 Rolland, Mme Nicole.29-17.-16 .768.16 9.12 Lemay, Jean-Guy.28-52.1,389.80 443.63 St-Jacques, André.16-1,-2 .487.18 19.38 Nault, Richard.16-30,-31.886.50 162.64 Dufresne, Mme Diane.15-43, PI5-44.342.08 6.66 (Mutation 298632-2/65) L'Heureux, Mme Graziella.24-23.938 12 39.05 Boutet, Antonio.16-34.507.30 61.65 Les immeubles susdits sont tous aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Thérèsc-de-Blain-ville, division d'enregistrement de Terrebonne, et situés dans la ville de Rosemère.The above immoveables are all on the official plan and in the book of the Parish of Ste-Thérèse-de-Blain-ville.Registry Division of Terrebonne, and situated in the Town of Rosemère. G A ZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.10 mai 1975.107e année, n\" 19 3863 Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes attachées auxdits immeubles.Donné à Rosemère, ce 24e jour d'avril, 1975.Copie certifié conforme.(Sceau) Le greffier de la ville, 60739-18-2-o Jeanne Lafleur.The said sale will be made with all active and passive servitudes, apparent or occult attached to the said properties.Given at Rosemère.this 24th Day of April.1975.Certified true copy.(Seal) Jeanne Lafleur.60739-18-2-0 Town Clerk.Cité de Sainl-I.riui.i¦ I Avis est par les présentes donne par la soussignée, greffier de la susdite municipalité, r school taxes, with the interest, plus the costs which shall subsequently be incurred unless the said taxes, interests and cost, be paid before the sale.Superficie Nom des propriétaires No fiche Cadastre en pi.car.Taxes Name of proprietors Card.No.Cadastral Area by sq.ft.Foti Delia Foresta, Dame/Afrs.Franceses.875-30 398T576 (avec bâtisse 20,608 $26,246.66 xcith buildino).Foti Delia Fore,i.i, Dame/Mrs.Franceses.875-31 398-577.21.106 3,199.47 Les immeubles ci-haut mentionnés sont du cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet.- Lesdites ventes seront en outre faites avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées aux immeubles.Donné en la Cité de Saint-Léonard, ce 28 avril 1975.Le greffier, 60813-19-2-o Micheline Mohamed, (Mme).The above immoveables are to the official plan ann Reference Book of the Parish of Sault-au-Récollet.The said sales will be made with all active and passive senitudes, apparent or occult, attached to the properties.Given at the City of Saint-Léonard, this April 28th, 1975.Micheline Mohamed, (Mrs.), 60813-19-2-o City Clerk.Cité du Cap-de-la-Madeleine Avis public est par les présentes donné que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère à l'Hôtel de Ville du Cap-de-la-Madeleine.VENDREDI, le TRENTIÈME jour de MAI 1975, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, avec intérêts, plus les frais subséquerament encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépens ne soient payés avant la vente.City of Cap-de-la-Madeleine Public notice is hereby given that the properties hereinafter described will be sold by public auction at the Town Hall of Cap-de-la-Madeleine, FRIDAY, the THIRTIETH day of the month of MAY, 1975, at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy the payment of the Municipal and School taxes, plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interests and costs be puid before the sale. 3864 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10.1975.Vol.107.No.19 La Commission municipale de Québec par décision en date du 25èmc jour d'avril 1975, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles, sous l'autorisation de la Loi des Cités et Villes, article 550.(Statuts refondus de la province de Québec.19(14.Chapitre 193).Noms des propriétaires Names of proprietors Brousseau, Robert.Frechette, Jean-Pou) Grenier, Louise.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes attachées auxdits immeubles.Donné en la Cité du Cap-de-la-Madeleine, ce vingt-neuvième jour d'avril 1975.Le greffier de la Cité, 60783-19-2-o Roland Desavlniebs, c.g.a.Municipalité du Comté de Mégantic AVIS PUBLIC est par le présent donné par René Chevrier, secrétaire-trésorier, que les terrains ci-dessous mentionnés seront vendus à l'enchère publique dans le Village d'Inverness.au lieu où le Conseil de Comté tient ses sessions.MERCREDI.le 11 juin, 1975.à dix heures du matin, tel que fixé par règlement, à défaut de paiement des taxes auxquelles ils sont affectés et des frais encourus.Municipalité d'Halifax-sud lo- Les lots Nos.641.642.643 et 644.du cadastre officiel de la Paroisse de St-Ferdinand.Canton d'Halifax, contenant 208 acres en superficie, plus ou moins.2o- La moitié nord-est du lot No.645.du même cadastre, contenant 50 acres en superficie, plus ou moins, bornée d'un bout au nord-est au chemin public et au cordon entre les rangs neuf el dix.à l'autre bout au sud-ouest à la moitié sud-ouest du même lot.appartenant à Armand Houle, ou son représentant, d'un côté au sud-est au lot No.643 et de l'autre côté au nord-ouest au lot No.646.A distraire du terrain en premier lieu décrit la partie sud-ouest du lot No.644, contenant 27 acres en superficie, plus ou moins, mesurant six arpents et demi de profondeur sur la largeur du lot.appartenant à Armand Houle.Avec toutes les bâtisses érigées sur la terre vendue.Connus comme appartenant à Ligouri Brochu.Taxes dues $1319.86 The Québec Municipal Commission by a decision dated the twenty-fifth day of April.1975, has authorized and abridged enumeration of the immoveables under the authority of Section 550 of the Cities and Towns Act, (Revised statutes of Québec.1964.Chap-tor 193).Cadastre Subdivisions Cadastral 550 120 549 74 387 61 The said sale will be made with all active and passive servitudes, apparent or occult attached to the said properties.Given in the town of Cap-de-la-Madeleine, this twenty-ninth day of April, 1975.Rolni) Desailniers, co.a., 60783-19-2-o Cily Clerk.Municipality of the county of Megantic PUBLIC NOTICE is hereby given by René Chevrier.secretary-treasurer, that the lands hereunder mentioned will be sold at public auction, in the village of Inverness, at the place where the county council helds its sittings, on WEDNESDAY, the eleventh of JUNE, 1975.at TEN o'clock, a.m.as enacted by a bylaw, in default of payment of taxes due thereon and costs incurred.Municipality of Halifax-South lo- The lots Nos 641.642 .643 and 644, of the official cadastre of the Parish of St-Ferdinand.Township of Halifax, containing 208 acres in superficies, more or less.2o- The north-east half of the lot No.645.of the same cadastre, containing 50 acres in superficies, more or less, bounded at one end to the north-east by the public road and at the division line between ranges nine and ten.at the other end to the south-west by the south-west half of the same lot, belonging to Armand Houle, or his representative, on one side to the south-east by the lot No.643 and at the other side to the north-west by the lot No.646.Save and except from the land above firstly described the south-west part of the lot No.644, containing 27 acres in superficies, more or less, measuring six arpents and a half in depth by the width of the lot, belonging to Armand Houle.With all the buildings erected on the land sold.Known as belonging to Ligouri Brochu.Taxes due $1319.86 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC.10mai 1975.107eannée, n' 19 3865 Municipalité de Robertsonville Un emplacement formant partie du lot No.10-A.rang 6, du cadastre officiel du Canton de Thetford.de la contenance de 50 pieds de largeur par 90 pieds de profondeur, plus ou moins, borné ledit emplacement en avant au chemin de front, à l'est au terrain de Louis Delisle ci-devant Louis Grenier, au sud au terrain d'Arthur Perron ci-devant Joseph Roy, à l'ouest au terrain d'Arthur Perron, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Connu comme appartenant à Lucien Lacroix.Taxes dues $399.82 Municipalité de St-Joseph de Coleraine Les lots 22 (superficie 98 acres) et 23 (superficie % acres), du rang \"B\".au cadastre officiel du Canton de Coleraine.Connus comme appartenant à la Suce.Richard N.Smith.Taxes dues $348.03 Le lot 19 du rang \"C\".ayant une superficie de 43 acres.Le lot 20.du rang \"C\".ayant une superficie de 47 acres.Le lot 21.du rang \"C\".ayant une superficie de 52 acres.Le lot 22.du rang \"C\".ayant une superficie de 54 acres.Le lot 23.du rang \"C\".ayant une superficie de 62 acres.Le lot 24, du rang \"C\".ayant une superficie de 66 acres.Le lot 25.du rang \"C\".ayant une superficie de 72 acres.Le lot 26, du rang \"C\", ayant une superficie de 77 acres.Le tout formant un total de 473 acres.Tous ces lots font partie du cadastre officiel du Canton de Coleraine.Connus comme appartenant à Mrs Monica W.H.Philips.Taxes dues $535.18 Les bâtisses érigées sur le lot No.338.du rang \"E\".du cadastre officiel du Canton de Coleraine.avec tous les droits d'occupation du terrain, lesquels sont sujets aux clauses stipulées dans le bail émis à l'occupant du terrain par le Ministère des Terres et Forêts du Québec.Le tout connu comme appartenant à René Gilbert.Taxes dues $98.21 Les bâtisses érigées sur le lot No.364, rang \"E\".du cadastre officiel du Canton de Coleraine, avec tous les droits d'occupation du terrain lesquels sont sujets aux clauses du bail émis à l'occupant du terrain par le Ministère des Terres et Forêts du Québec.Le tout connu comme appartenant à François Trottier.Taxes dues $267.22 Un morceau de terrain de 65 pieds de largeur par 100 pieds de profondeur environ, connu sous le No.2-49.étant une partie de la subdivision du lot 2 du rang 6.du cadastre officiel du Canton de Coleraine.La façade dudit terrain donnant sur la rue Cadorette au Domaine des Pins (Maisons mobiles).Connu comme appartenant à Drummond Mobile.Taxes dues $126.80 Municipality of Robertsonville An emplacement formant part of the lot No.10-A.Range 6.of the official cadastre of the Township of Thetford.containing 50 feet in width by 90 feet in depth, more or less, bounded the said emplacement in front by the front road, to the east by the land of Louis Delisle heretofore Louis Grenier, to the south by the land of Arthur Perron, heretofore Joseph Roy.to the west by the land of Arthur Perron, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Known as belonging to Lucien Lacroix.Taxes due $399.82 Municipality of St-Joseph de Coleraine The lots 22 (superficies 98 acres) and 23 (superficies % acres), range \"B\".of the official cadastre of Ihe Township of Coleraine.Known as belonging to Estate Richard N.Smith.Taxes due $348.03 The lot 19.range \"C\".having a superficies of 43 acres.The lot 20.range \"C\".having a superficies of 47 acres.The lot 21.range \"C\".having a superficies of 52 acres.The lot 22.range \"C\".having a superficies of 54 acres.The lot 23.range \"C\".having a superficies of 62 acres.The lot 24.range \"C\".having a superficies of 66 acres.The lot 25.range \"C\".having a superficies of 72 acres.The lot 26, range \"C\", having a superficies of 77 acres.The whole forming a total of 473 acres.All that lots forming part of the official cadastre of the Township of Coleraine.Known as belonging to Mrs.Monica W.H.Philips.Taxes due $535.18 The buildings erected on the lot No.338.range \"E\".of the official cadastre of the Township of Coleraine.with all the rights of occupation on the said land, which are subject to the clauses stipulated in the lease issued to the occupant of the land by the Department of the Lands and Forests of Québec.Known as belonging to René Gilbert.Taxes due $98.21 The buildings erected on the lot No.364.Range \"E\".of the official cadastre of the Township of Coleraine.with all the rights of occupation on the said land which are subject to the clauses of the lease issued by the Department of the Lands and Forests of Québec.Known as belonging to François Trottier.Taxes due $267.22 A piece of land of 65 feet in width by 100 feet in depth or about, known as the lot No.2-49.being a part of the subdivision of the lot 2.range 6.of the official cadastre of the Township of Coleraine.The fronting of the said land being on the Cadorette street to the Domaine des Pins (Maisons mobiles).Known as belonging to Drummond Mobile.Taxes due $126.80 3866 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10.1975.Vol.107.No.19 Municipalité de St-Pierre Baptiste Tous les droits d'occupation de Richard côté, Jules Breton et Serge Turmel sur une partie du lot No.830, du cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Sophie, Canton d'Halifax, mesurant 180 pieds de largeur sur le chemin public par 101'/: pieds de profondeur, bornée en front au nord-est au chemin public ou chemin de front entre les rangs neuf et dix.en profondeur au sud-ouest et d'un côté au nord-ouest au résidu dudit lot No.830 appartenant à Léo Paradis et de l'autre côté au sud-est au lot No.829.Connus comme appartenant à Richard Côté.Jules Breton et Serge Turmel.Taxes dues $15.76 Une partie du lot No.795.du cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Sophie.Canton d'Halifax, mesurant 210 pieds de largeur en avant au sud-ouest, le long du terrain appartenant déjà à l'acquéreur, et 210 pieds de largeur en arrière au nord-est par 190 pieds de profondeur dans les deux lignes, bornée en front au sud-ouest au terrain appartenant déjà à l'acquéreur et acquis du Club Auto-Neige des Bois-Francs Inc., faisant partie du même lot, ou à une distance de 160 pieds du chemin public entre les rangs neuf et dix.en arrière au nord-est et du côté nord-ouest au résidu du même lot restant la propriété de Philemon Guillemette et Noël Poirier et de l'autre côté au sud-est à la ligne de division entre les lots Nos.795 et 796.Connue comme appartenant à Richard Nolet.Taxes dues $125.12 Une partie du lot No.237.du cadastre officiel du Canton d'Inverness, mesurant 100 pieds de largeur en avant et en arrière par 200 pieds de profondeur, dans les deux lignes, bornée en front au sud-est au lac Joseph, en arrière au nord-ouest et d'un côté au nord-est par le résidu du même lot appartenant à Maurice Pelletier, et de l'autre côté au sud-ouest au terrain d'Emilien Pomerleau ou à 300 pieds de la ligne du cordon entre les rangs trois et quatre.Avec un droit de passage sur les lots Nos.237 et 238, du même cadastre, le tout tel que mentionbé audit acte.Connue comme appartenant à Réjean Pomerleau.Taxes dues $13.09 Municipality of St-Pierre Baptiste All the rights of occupation of Richard Côté, Jules Breton and Serge Turmel on a part of the lot No.830.of the Official cadastre of the Parish of Ste-Sophie.Township of Halifax, measuring 180 feet in width on the public road by 101 Vz feet in depth, bounded in front to the north-east by the public road or front road between ranges nine and ten, in depth to the south-west and on one side to the north-west by the residue of the said lot No.830 belonging to Léo Paradis and on the other side to the south-east by the lot No.829.Known as belonging to Richard Côté.Jules Breton and Serge Turmel.Taxes due $15.76 A part of the lot No.795.of the official cadastre of the Parish of Ste-Sophie.Township of Halifax, measuring 210 feet in width in front to the south-west, along the land already belonging to the purchaser, and 210 feet in width at the rear to die north-east by 190 feet in depth on both lines, bounded in front to the south-west by the land already belonging to the purchaser and acquired from Club Auto-Neige des Bois-Francs Inc.forming part of the same lot.or at a distance of 160 feet from the public road between ranges nine and ten.at the rear to the north-east and on the north-west side by the residue of the same lot remaining the property of Philemon Guillemette and Noël Poirier and on the other side to the south-east by the division line between lots Nos.795 and 7%.Known as belonging to Richard Nolet.Taxes due $125.12 A part of the lot No.237.of the official cadastre of the Township of Inverness, measuring 100 feet in width in front and at the rear by 200 feet in depth, on both lines, bounded in front to the south-east by the lake Joseph, in rear to the north-west and on one side to the north-east by the residue of the same lot belonging to Maurice Pelletier, and on the other side to the south-west by the land of Emilien Pomerleau or at 300 feet from the division line between ranges three and four.With a right of way on the lots Nos.237 and 238.of the same cadastre, the whole as mentioned in the said deed.Known as belonging to Réjean Pomerleau.Taxes due $13.09 Municipalité de Plessisville Par.La bâtisse érigée sur une partie du lot No.129, du cadastre officiel de la Municipalité de Somerset-Sud.Connue comme appartenant à Emile Breton.Taxes dues $68.52 Inverness, le 28 avril 1975.Municipality of the Parish of Plessisville The building erected on a part of the lot No.129, of the official cadastre of the Municipality of Somerset-South.Known as belonging to Emile Breton.Taxes due $68.52 Inverness.April 28, 1975.Le secrétaire-trésorier rené Chevrier.René Chevrier.Secretary-Treasurer. GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC.W mai 1975.107e année, n\" 19 3867 Société d'habitation du Québec Québec Housing Corporation Cité de Thetford Mines Programme de renovation « Secteurs Saint-Maurice, Mitchell et Smith » (Modifications) Avis est donné qu'en vertu de l'article 40de la Loi de la Société d'habitation du Québec (1966/1967.chapitre 55), le lieutenant-gouverneur en conseil a, par l'arrêté en conseil numéro 1657-75.en date du 23 avril 1975, ratifié les modifications adoptées par le règlement numéro 983 en date du 17 mars 1975 de la cité de Thetford Mines à son programme de rénovation pour la partie de son territoire appelée » Secteurs Saint-Maurice, Mitchell et Smith ».La Société d'habitation du Québec a.par sa résolution numéro 8334 en date du 14 avril 1975, approuvé ces modifications.City of Thetford Mines Renewal program \"Secteurs Saint-Maurice.Mitchell and Smith\" (Modifications) Notice is hereby given that pursuant to section 40 of the Québec Housing Corporation Act ( 1966/1967.Chapter 55), the Lieutenani-Govemor in Council has.by Order number 1657-75 dated April 23.1975.ratified the modifications adopted by by-law number 983 dated March 17.1975 of Ihe City of Thetford Mines in its renewal program for the part of its territory known as \"Secteurs Saint-Maurice.Mitchell and Smith\".The Québec Housing Corporation has.by it resolution number 8334 dated April 14, 1975.approved these modifications.60806-O Le Secrétaire.Me Jean-Luc Lesage.notaire.60806-O Secretary, Me Jean-Luc Lesage.Notary.Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses CALIFORNIA COMPUTER PRODUCTS.INC.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie - CALIFORNIA COMPUTER PRODUCTS, INC.», a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal.aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est C.T.Corporation System (Canada).Ltd., 220.Grande-Allée est, Québec.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 220.Grande-Allée est.Québec, district judiciaire de Québec.60757-o Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives.Albert Jessop.1362-5645 CALIFORNIA COMPUTER PRODUCTS, INC.Notice is given that under the Extra-Provincial Companies Act, \"CALIFORNIA COMPUTER PRODUCTS.INC.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the company is C.T.Corporation System (Canada) Ltd., 220 Grande-Allée East.Québec City.The head office of the Company in the Province is located at 220 Grande-Allée East.Québec City.Judicial District of Québec.Albert Jessop.Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.60757 1362-5645 3868 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10.1975.Vol.107.No.19 DWS HOLDINGS INC.Notice is given that under the Extra-Provincial Companies Act.\"DWS HOLDINGS INC.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the Company is Mr.Fred Mills.2075 University Street.Office 1000.Montreal.The head office of the Company in the Province is located at 2075 University Street.Office 1000.Montreal.Judicial District of Montreal.Albert Jessop.Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.60757 1362-7443 EASTERN AIR LINES, INC.Notice is given that under the Extra-Provincial Companies Act.\"EASTERN AIR LINES, INC.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the Company is Mr.Nicolaas G.Dykstra.255 Rose Alma Street.Rosemère.The head office of the Company in the Province is located at the Montreal International Airport, in Dorval.Judicial District of Montreal.Albert Jessop.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60757 1362-0521 Syndicats professionnels SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PODIATRES, P.Q.(Loi des syndicats professionnels ) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 21 mars 1975.il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PODIATRES.P.Q.», avec siège social situé au numéro 995.avenue Myrand.Sainte-Foy.district judiciaire Québec.Le sous-minislre des institutions financières.compagnies et coopératives.60830-O Albert Jessop.60830-O SP.1359-8131 EASTERN AIR LINES, INC.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « EASTERN AIR LINES.INC.», a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Nicolaas G.Dykstra.255, rue Rose Aima, Rosemère.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à Aéroport International de Montréal.Dorval.district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Albert Jessop.60757-e 1362-0521 DWS HOLDINGS INC.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « DWS HOLDINGS INC.».a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Fred Mills.2075.rue University, bureau 1000.Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 2075.rue University, bureau 1000.Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies el coopératives, Albert Jessop.60757-0 1362-7443 Professional Syndicates SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PODIATRES.P.Q.(Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice that on March 21.1975.he authorized the constitution of a professional syndicate under the name of \"SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PODIATRES.P.Q.\".with head office located at 995 Myrand Avenue.Sainte-Foy.Judicial District of Québec.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.60830 SP.1359-8131 G A ZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 10 mai 1975.107e année.n° 19 3869 SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOVINS DE LA REGION DES LAURENTIDES (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 18 mars 1975.il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de - SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOVINS DE LA REGION DES LAURENTIDES ».avec siège social à Saint-Eustache, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-minislre des institutions financières.compagnies et coopératives.Albert Jessop.60797-O 1362-1487 SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOVINS DE LA REGION DES LAURENTIDES (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice that on March 18.1975.he authorized the constitution of a professional syndicate under the name of \"SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOVINS DE LA REGION DES LAURENTIDES\".with its head office located in Saint-Eustache.Judicial District of Terrebonne.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.60797 1362-1487 L'UNION DES OUVRIERS DU TEXTILE-COTON DE DRUMMONDVILLE INC.(Loi des syndicats professionnels) The Minister of Financial Institutions.Compagnies and Cooperatives, pursuant to section 25 of the Professional Syndicates Act, enacts the termination of the corporate existence of \"L'UNION DES OUVRIERS DU TEXTILE-COTON DE DRUMMONDVILLE INC.\".incorporated on February 11.1942.Marc Carrier.Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.60592 SP: 125-42 L'UNION DES OUVRIERS DU TEXTILE-COTON DE DRUMMONDVILLE INC.(Professional Syndicates Act) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, en vertu de l'article 25 de la Loi des syndicats professionnels, décrète la fin de l'existence corporative de « L'UNION DES OUVRIERS DU TEXTILE-COTON DE DRUMMONDVILLE INC.».constitué le II février 1942.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives.Marc Carrier.60592-O SP: 125-42 Office des professions du Québec Québec Profession Board Avis de radiation permanente L'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 176 du Code des professions.(L.Q., 1973, ch.43).que Me Harold Bloomfield.ayant exercé sa profession à Montréal, a été radié d'une façon permanente du tableau du Barreau du Québec en vertu d'une décision définitive du Comité de discipline rendue le 5 mars 1975.Le secrétaire de l'Office des professions du Québec, 60799-O Edouard Champoux.Notice of permanent striking off The Québec Professions Board hereby gives notice, in conformity with section 176 of the Professional Code (S.Q.1973.Chapter 43).that Mr Harold Bloomfield.who has practised his profession in Montreal, has been permanently struck off the roll of the Bar of the Province of Québec, pursuant to a final decision of the Committee on Discipline rendered on March 5.1975.60799 Edouard Champoux.Secretary of the Québec Professions Board. 3870 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Mav 10.1975.Vol.107.No.19 Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Révocation de dissolution Le ministre des institutions financières, compagnies, et coopératives donne avis.en vertu du paragraphe a de l'article 5/ de la Loi des renseignements sur les compagnies, qu'il a jugé à propos de faire droit à la demande d'intéressés faite dans les délais légaux à l'effet de révoquer la dissolution de Nom des compagnies Revocation of dissolution The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice, that pursuant to paragraph a of section 5 / of the Companies Information Act.he deemed it advisable to grant the petition of the interested parties made within the legal time limit, praying to revoke the dissolution of Name of the Companies Nom des compagnies Name of the companies Dissolution Date Gazette officielle ne Official Gazelle No ARCADIA MINERALS LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) COMITE DES LOISIRS DE BREAKEYVILLE INC.DURAND-MERCIER LIMITEE.LA MANUFACTURE DE MANCHES BOISVERT & CIE LTEE .et sa version anglaise BOISVERT HANDLE MANUFACTURING CO.LTD.OSBORNE REFRIGERATION SALES & SERVICE INC .FERNANDO ST-HILAIRE LIMITEE .ST-JOHNSBURY TRUCKING CO.LTD .SERVICE DES LOISIRS ST-ZOTIQUE .WINDSOR TRANSPORT INC.12\t10\t74\t41 07\t12\t74\t49 02\t11\t74\t44 27\t07\t74\t30 09\tII\t74\t45 22\t03\t75\t12 08\t12\t73\t49 27\t04\t74\t17 19\t10\t74\t42 en vertu de ladite loi et qu'il révoque la dissolution desdites compagnies.En conséquence, lesdites compagnies sont censées n'avoir jamais été dissoutes en vertu de ladite loi.sans préjudice aux droits acquis par toute personne entre la dissolution et la révocation.pursuant to the said Act and that he revokes the dissolution of the said companies.Consequently, the said companies are considered as having never been dissolved under the said Act, without prejudice to the rights acquired by any person between the dissolution and the revocation.Le directeur du service des compagnies.Pierre Desjardins.60757-o Pierre Desjardins.60757-0 Director of the Companies Service. G A ZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.10 mai 1975.107e année, n\" 19 3871 Liquidation \u2014 Loi de la PRATTE & COMPAGNIE LTEE et sa version anglaise PRATTE & COMPANY LTD.Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie.- PRATTE & COMPAGNIE LTEE et sa version anglaise PRATTE & COMPANY LTD.».tenue à Québec, le 31 décembre 1974, il a été résolu que les affaires de ladite compagnie soient liquidées, et que celle-ci soit dissoute, en vertu de la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.André Phillips, comptable, a été nommé liquidateur.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.60772-O 2081-36 CHRISTINE LTD.Avis est donné que la compagnie « CHRISTINE LTD.», constituée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 2 mai 1958.avec siège social à Montréal, a été dissoute le 17 avril 1975.en vertu de la Loi de la liquidation des compagnies.Le directeur du service des compagnies.Pierre Desjardins.60773-o 11537-58 CO-OP FORESTIERE SACRE-COEUR (Loi des associations coopératives) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de l'association coopérative « CO-OP FORESTIERE SACRE-COEUR ».tenue à Sacré-Coeur, dans le district électoral de Saguenay.le I7avril 1974.il a été résolu de liquider la coopérative et qu'elle soit dissoute, ce conformément aux dispositions de la Loi des associations coopératives et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que MM.Guy Deschênes.Jean-Philippe Simard et Alexis Bouchard soient nommés liquidateurs.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives.600798-o Albert Jessop.Winding-Up Act PRATTE & COMPAGNIE LTEE and its English version PRATTE & COMPANY LTD.Notice is given that, at a special general meeting of the shareholders of \"PRATTE & COMPAGNIE LTEE and its English version PRATTE & COMPANY LTD.\".held in Québec, on December 31, 1974.it was resolved that the affairs of said company be wound up and thai Ihe latter be dissolved, pursuant to the Winding-Up Act.and that Mr.André Phillips, accountant, be appointed liquidator.Pierre Desjardins.Director of the companies service.60772 2081-36 CHRISTINE LTD.Notice is given that \"CHRISTINE LTD.\".incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated May 22.1958.having its head office in Montreal, was dissolved on April 17.1975, pursuant to the Winding-Up Act.Pierre Desjardins.Director of the Companies Service.60773 11537-58 CO-OP FORESTIERE SACRE-COEUR {Cooperative Associations Act) Notice is given that at a special general meeting of the members of the cooperative association \"CO-OP FORESTIERE SACRE-COEUR\" held in Sacré-Coeur, in the Electoral District of Saguenay.on April 17.1974.it was resolved that Ihe cooperative be wound-up and that it be dissolved, the foregoing pursuant to the provisions of the Cooperative Associations Act and of the Winding-Up Act.and that Messrs.Guy Deschênes.Jean-Philippe Simard and Alexis Bouchard be appointed liquidators.Albert Jessop.Deputy Minister of Financial Institutions.60798 Companies and Cooperatives. 3872 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 10.1975.Vol.107.No.19 ARRETES EN CONSEIL ORDERS IN COUNCIL Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1587-75 Québec, le 23 avril 1975.Présent : le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'annexion d'un certain territoire, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire des Cèdres.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'éducation : Que les lots 11 à 18 inclusivement du rang VII du cadastre officiel du canton d'Aylmer, dans le comté de Frontenac, soient détachés de la municipalité du Lac-Mégantic et annexés, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire des Cèdres.et ce.conformément aux articles 46 et 49 de la Loi de l'instruction publique.Statuts refondus, 1964, chapitre 235.Le greffier du Conseil exécutif.60835-0 Julien Chouinard.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1588-75 Québec, le 13 avril 1975.Présent : le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'annexion d'un territoire, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire du Lac-Mégantic.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'éducation : Que les lots 20 à 28 inclusivement du rang VIII du cadastre officiel du canton Lambton.dans le comté de Frontenac, soient détachés de la municipalité scolaire des Cèdres et annexés, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire du Lac-Mégantic.et ce, conformément aux articles 46 et 49 de la Loi de l'instruction publique, Statuts refondus, 1964.chapitre 235.Order in Council Executive Council Chamber Number 1587-75 Québec, April 23.1975.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting the annexation of a certain territory, for Roman Catholics only, to the Des Cèdres School Municipality.It is ordered upon recommendation of the Minister of Education: That lots 11 to 18 inclusive, in Range VII on the official cadastre for the Township of Aylmer.in the County of Frontenac, be detached from the Lac-Mégantic School Municipality and annexed, for Roman Catholics only, to the Des Cèdres School Municipality.the foregoing, in conformity with sections 46 and 49 of the Education Act.Revised Statutes.1964.Chapter 235.Julien Chouinard, 60835 Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 1588-75 Québec.April 23.1975.Present: The lieutenant-Governor in Council.Respecting the annexation of a territory, for Roman Catholics only, to the Lac-Mégantic School Municipality.It is ordered upon the recommendation of the Minister of Education: That lots 20 to 28 inclusive, in Range VIII.on the official cadastre for the Township of Lambton, in the County of Frontenac, be detached from the Des Cèdres School Municipality and annexed, for Roman Catholics only, to the Lac-Mégantic School Municipality, the foregoing, in conformity with sections 46 and 49 of the Education Act.Revised Statutes.1964.Chapter 235.60835-o Le greffier du conseil exécutif, Julien Chouinard.60835 Julien Chouinard.Clerk of the Executive Council. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.10mai 1975.107eannée.n° 19 Proclamations Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que, sous l'autorité de l'article 2 de la Loi des titres de propriété dans certains districts électoraux (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 321), le ministre des terres et forêts a fait dresser des plan et livre de renvoi revisés, dans le district électoral de Saguenay, pour le cadastre d'une partie du canton De Monts, à l'endroit des lots 1 à 4, 7, 11 à 30, 34 à 55.76, 97 à 161, le bloc O et les lots 1 à 31 du bloc S de Baie-Trinité-Est, les lots « A » et « B » de la rivière Grande-Trinité, le lot « A » côté nord de l'embouchure de la rivière Grande-Trinité et l'Ile numéro 15 des Iles du golfe Saint-Laurent et de leurs subdivisions respectives, le tout situé dans la division d'enregistrement de Saguenay; Attendu que, conformément aux articles 2 et 3 de ladite Loi, le ministre des terres et forêts a fait déposer: 1.le 18 novembre 1974, aux archives du ministère des terres et forêts, à Québec, ces plan et livre de renvoi; 2.le 21 novembre 1974, au bureau de la division d'enregistrement de Saguenay, à Baie-Comeau, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi; 3.le 20 novembre 1974, au bureau désigné par lui, à savoir celui du secrétaire-trésorier de la corporation municipale du village de Baie-Trinité, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi; Attendu Qu'il y a maintenant lieu d'émettre la proclamation prévue à l'article 4 de ladite Loi.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 896-75, du 5 mars 1975, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi des titres de propriété dans certains districts électoraux (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 321), qu'il y a lieu: a) de fixer à la date de la deuxième et dernière publication consécutive de cette proclamation dans la Gazelle officielle du Québec, l'entrée en vigueur des plan et livre de renvoi révisés, dans le district électoral de Proclamations Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern.Greeting.Proclamation Whereas, under the provisions of section 2 of Certain Electoral Districts Land Titles Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 321), the Minister of Lands and Forests has caused to be drawn up a revised plan and book of reference in the Electoral District of Saguenay, for the cadastre of a part of the Township of De Monts, with regard to lots 1 to 4, 7, 11 to 30, 34 to 55, 76, 97 to 161, block O and lot 1 to 31 of block S in Baie-Trinité-East, lots \"A\" and \"B\" of the Grande-Trinité River, lot \"A\" north side of the mouth of the Grande-Trinité River and Island number 15 of the islands of the Gulf of St.Lawrence and their respective subdivisions, the whole located in the Saguenay Registration Division; Whereas, in conformity with sections 2 and 3 of said Act, the Minister of Lands and Forests has caused to be deposited : 1.on November 18, 1974 in the Archives of the Department of Lands and Forests, in Québec, this plan and book of reference; 2.on November 21, 1974 in the Saguenay Registration Division Office, in Baie-Comeau, a certified copy of said plan and book of reference; 3.on November 20, 1974 in the office designated by him, namely that of the Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of the Village of Baie-Trinité, a certified copy of said plan and book of reference; Whereas it is now expedient to issue the proclamation provided for in section 4 of said Act.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 896-75, dated March 5, 1975.We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and in conformity with sections 2.3, 4 and 5 of the Certain Electoral' Districts Land Titles Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 321), that it is expedient: (a) To fix the date of t he second and final consecutive publication of this proclamation in the Québec Official Gazette as the date of the coming into force of the revised plan and book of reference, in the Electoral 3874 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10.1975.Vol.107.No.19 Saguenay, pour le cadastre d'une partie du canton de De Monts, à l'endroit des lots 1 à 4, 7, 11 à 30, 34 à 55, 76, 97 à 161, le bloc O et les lots 1 à 31 du bloc S de Baie-Trinité-Est, les lots « A » et « B » de la rivière Grande-Trinité, le lot « A » côté nord de l'embouchure de la rivière Grande-Trinité et l'île numéro 15 des îles du golfe Saint-Laurent et de leurs subdivisions respectives, le tout situé dans la division d'enregistrement de Saguenay; 6) d'indiquer que ces plan et livre de renvoi révisés sont déposés aux archives du ministères des terres et forêts, à Québec, et, qu'en outre, le ministre des terres et forêts a fait déposer une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi revisés au bureau de la division d'enregistrement de Saguenay, à Baie-Comeau, ainsi qu'au bureau désigné par lui, à savoir celui du secrétaire-trésorier de la corporation municipale du village de Baie-Trinité.c) d'informer le public que, pendant les huit mois (8) qui suivront la deuxième et dernière publication de cette proclamation dans la Gazelle officielle du Québec, tout intéressé pourra consulter gratuitement lesdits plan et livre de renvoi revisés; d) porter notification qu'à l'expiration de ce délai, le ministre des terres et forêts délivrera un certificat de propriété à tout occupant de l'immeuble avec ou sans titre, même s'il n'est qu'administrateur ou simple exploitant, à moins d'opposition écrite d'un intéressé; e) d'ordonner que tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire susdit pour lequel un plan et un livre de renvoi révisés ont été déposés soit renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par les articles 2172 à 2172a du Code civil; /) d'informer aussi le public que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icellcs apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce cinquième jour de mars en l'année mil neuf cent soixante-quinze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-quatrième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Libro: 502 René Laxgevin.Folio: 85 60691-18-2-o District of Saguenay, for the cadastre of a part of the Township of De Monts, with regard to lots 1 to 4, 7, 11 to 30, 34 to 55, 76, 97 to 161, block O and lots 1 to 31 of block S of Baie-Trinité-East, lots \"A\" and \"B\" of the Grande-Trinité River, lot \"A\" north side of the mouth of the Grande-Trinité River and island number 15 of the islands of the Gulf of St.Lawrence and their respective subdivisions, the whole located in the Saguenay Registration Division; (6) To state that the said revised plan and book of reference have been deposited in the Archives of the Department of Lands and Forests, in Québec, and that moreover, the Minister of Lands and Forests has caused a certified copy of said revised plan and book of reference to be deposited in the Saguenay Registration Division, in Baie-Comeau, as well as in an office designated by him, namely that of the Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of the Village of Baie-Trinité; (c) To inform the public that during the eight months following upon the second and final publication of this proclamation in the Québec Official Gazette, any interested party may consult, without charge, the said revised plan and book of reference; (d) To give notice that when such time limit expires, the Minister of Lands and Forests will issue a certificate of ownership to any occupant of the immoveable, with or without title, even though he be only an administrator or an operator of such immoveable, unless an interested party objects in writing; (e) To order that any real right affecting a lot comprised in the aforesaid territory for which a revised plan and book of reference have been deposited be renewed, within the same period, in the manner prescribed by articles 2172 and 2172a of the Civil Code; (/) Also to inform the public that, failing such renewal, the real rights preserved by the first registration shall have no effect as regards other creditors or subsequent purchasers whose rights are duly registered.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this fifth day of March in the year of Our Lord, one thousand nine hundred seventy-five and in the twenty-fourth year of Our Reign.By command, René Langevin, Libro: 502 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 85 60691-18-2 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.10mai 1975.107eannée, n'19 3875 COOPERATIVE D'HABITATION L'ORMIERE DE NEUFCHVTEL (Loi des associations coopératives) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu de la Loi des associations coopératives, il a approuvé la formation d'une association sous le nom de « COOPERATIVE D'HABITATION L'ORMIERE DE NEUFCHA-TEL », dont le siège social est situé à Neufchâtel, Québec, dans le district électoral de Chauveau.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 60800-o Albert Jessop.COOPERATIVE D'HABITATION L'ORMIERE DE NEUFCHATEL (Cooperative Associations Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that under the Cooperative Associations Act, he has approved the formation of a cooperative association under the name of \"COOPERATIVE D'HABITATION L'ORMIERE DE NEUFCHATEL\", with its head office located in Neufchâtel, Québec, in the Electoral District of Chauveau.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60800 Companies and Cooperatives.CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DE VILLE-MERCIER (Loi des associations coopératives) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la Loi des associations coopératives, il a approuvé la formation d'une association sous le nom de « CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DE VILLE-MERCIER - dont le siège social est situé à Mercier dans le district électoral de Châteauguay.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 60826-0 Albert Jessop.CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DE VILLE-MERCIER (Cooperative Associations Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has given notice that, under the Cooperative Associations Act, he has approved the formation of an association under the name of \"CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DE VILLE-MERCIER\".The head office of this Association is located in Mercier, in the Electoral District of Châteauguay.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60826 Companies and Cooperatives.COOPERATIVE D'HABITATION LE VILLAGE DE COTE-DES-NEIGES (Loi des associations coopératives) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu de la Loi des associations coopératives, il a approuvé la formation d'une association sous le nom de « COOPERATIVE D'HABITATION LE VILLAGE DE-COTE-DES-NEIGES », dont le siège social est situé à Montréal, Québec, dans le district électoral d'Outremont.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 60828-o Albert Jessop.COOPERATIVE D'HABITATION LE VILLAGE DE COTE-DES-NEIGES (Cooperative Associations Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to the Cooperative Associations Act, he has approved the formation of a cooperative association under the name of \"COOPERATIVE D'HABITATION LE VILLAGE DE COTE-DES-NEIGES\".whose head office is located in Montreal, Québec, in the Electoral district of Outremont.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60828 Companies and Cooperatives.COOPERATIVE D'HABITATION PLACE NEUVIALE (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement spécial adopté le 14 avril 1975.de l'association coopérative co-op-Habitat de Duberger » changeant son nom en celui de « COOPERATIVE D'HA- COOPERATIVE D'HABITATION PLACE NEUVIALE (Cooperative Associations Ad) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the scpcial bylaw adopted on April 14, 1975 by the cooperative association \"Association coopérative co-op-Habitat de Duberger\".changing its name to that of Associations coopératives Cooperative Associations 3876 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10.1975.Vol.107.No.19 BITATION PLACE NEUVIA1.E », changeant son siège social de Duberger dans le district électoral de St-Sauveur, à Québec dans le district électoral de Vanier, augmentant le montant de la part sociale de $1 à §20 et modifiant ses fins.' Le sou-i-mùiislre de.i institutions financières.compagnies el coopératives, 60827-o Albert Jessop.\"COOPERATIVE D'HABITATION PLACE NEU-VTALE\", transferring its head office from Duberger, in the Electoral District of Saint-Sauveur, to Québec, in the Electoral District of Vanier, increasing the amount of the capital share from $1 to $20, and modifying its purposes.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60827 Companies and Cooperatives.Vente d'effets non réclamés Sale of Unclaimed Baggage LA CIE DES MESSAGERIES CP LIMITEE Avis est par les présentes donné que tous les effets reçus avant le 1er jour de juin, 1974.et non réclamés aux bureaux des CP Express limitée à divers endroits de la province de Québec, seront vendus aux enchères publiques au plus haut enchérisseur par Frank Wad-dington, encanteur, 189 est, rue Queen, Toronto, Ontario, à onze heures du matin, le 5e jour de juin, 1975, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.Le vice-président, 60755-18-6-o W.M.Riley.CP EXPRESS LIMITED Notice is hereby given that all goods received previous to the first day of June, 1974, still remaining unclaimed in the offices of the CP Express Limited at different points in the Province of Québec, will be sold at public auction to the highest bidder by Frank Wad-dington, auctioneer, at 189 Queen Street East, Toronto, Ontario, at eleven o'clock in the forenoon, on the fifth day of June, 1975, unless same shall be called for before that date and all charges paid thereon.W.M.Riley, 60755-18-6-0 Vice-President.Ventes par Shérifs Sheriff's Sales AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI ABITIBI Fieri Facias Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure, f T ES ARTISANS, SOCIETE CO-No 605-05-000, J ^ OPERATIVE D'ASSURAN-271-73-0.) CE-VIE, corporation légalement ' constituée, ayant son siège social au numéro 333 est de la rue Craig dans les villes et district de Montréal, demanderesse, s LES ENTREPRISES GALOR LTEE, corporation légalement constituée, ayant son siège social au numéro 167, chemin Baie Carrière, à Val d'Or, district d'Abitibi, défenderesse.« Un lot de terre connu et désigné aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour le canton Bourla-maque sous le numéro mille cent quatre-vingt-deux (1182) avec la bâtisse y érigée et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement au Palais de Justice d'Amos, le VINGT-SIXIÈME jour de JUIN 1975, à TROIS heures de l'après-midi.Le shérif.Bureau du shérif, Laval Goulet.Amos, le 21 avril 1975.60790-o Fieri Facias Canada \u2014 Province of Québec Superior Court.(T ES ARTISANS.SOCIETE CO-No.605-05-000, J J-' OPERATIVE D'ASSURANCE-271-74-0.j VIE, a corporation legally incorpo-V rated, having its head office at 333 Craig Street East, in the City and District of Montreal, plaintiff, M LES ENTREPRISES GALOR LTEE, a corporation legally incorporated, having its head office at 167 Baie Carrière Road, in Val d'Or, District of Abitibi, defendant.\"A piece of land known and described on the official plan and in the book of reference for the Township of Bourlamaque as number one thousand one hundred eighty-two (1182), with the building erected thereon and dependencies.\" To be sold at the Registry Office in the Court House of Amos, on the TWENTY-SIXTH day of JUNE, 1975, al THREE o'clock in the afternoon.Laval Goulet, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, April 21, 1975.60790 G A ZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.10 mai 1975.107e année, n\" 19 3877 BEAUCE Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Beauce { JEAN FECTEAU, Ste-Marie, comté No 26,116.\\ J de Beauce.demandeur, vs DONAT l LANDRY.St-Jean-de-la-Lande, comté de Beauce, défendeur.Pour être vendu l'immeuble suivant : « Un emplacement situé à St-Jean-de-la-Lande, comté de Beauce, connu et désigné comme étant une partie du lot no cent quatre-vingt-quinze (Ptie 195) du cadastre officiel de la paroisse de St-Georges, comté de Beau-ce, avec toutes bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Cet emplacement mesure, en mesures anglaises, deux cents pieds (200') de profondeur dans ses lignes nord-est et sud-ouest sur deux cent soixante-quinze pieds (275') de largeur des deux autres côtés.Cet emplacement est borné vers le nord-ouest au chemin de front du rang; vers le sud-ouest au lot no cent quatre-vingt-seize (196) dudit cadastre appartenant à M.Raoul Thibaudeau et vers le sud-est et le nord-est au résidu du lot no cent quatre-vingt-quinze (195) appartenant à Raoul Thibaudeau.Avec la servitude d'aqueduc existant en vertu du contrat enregistré à Beauce sous le no 214,165 et sujet à toutes servitudes passives pouvant affecter l'immeuble ci-dessus vendu suivant titres enregistrés.» Pour être vendu le 10 juin 1975 au bureau d'enregistrement de la division de Beauce à Beauceville à 10 heures de l'avant-midi.Le shérif, 297, avenue du Palais J.Claude Morin.St-Joseph-de-Beauce 60791-o GOS 2V0 BEAUCE Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Beauce ( JEAN FECTEAU, Sainte-Marie, No.26,116.< J County of Beauce, plaintiff, vs DE LA CITE ET DU DIS- l TRICT DE MONTREAL, corporation légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au 266 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal, demanderesse, vs CHARLES ITZCOVITCH, résidant et domicilié au 6600, Kildard Rd, app.1208, à Côte-St-Luc, district judiciaire de Montréal, IRVING LEONARD ITZCOVITCH, résidant et domicilié au 410, Canterbury Square, en la cité de Laval, district judiciaire de Montréal, SYDNEY ITZCOVITCH.résidant et domicilié au 5604, avenue Westluke, à C6te-St-Luc, district judiciaire de Montréal, défendeurs, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Montréal, des cité et district de Montréal, mis en cause.« Un certain emplacement ayant front sur l'avenue Argyle, en la cité de Verdun, district de Montréal, connu et désigné comme étant la subdivision numéro cent quatre du lot originaire numéro quatre mille six cent soixante-treize (4673-104) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Montréal, mesurant \"All the right, title and interest of tl.c diii.,.t emphyteutic lessee of the immoveable property Ltrt in-after described, namely: An emplacement situate at the corner of St-Urbain and Prince Arthur Streets in the City of Montreal, in the Province of Québec, composed of subdivision A of subdivision ninety-two, subdivisions A and B of subdivision ninety-three, subdivisions A and B of subdivision ninety-four and subdivision ninety-five, all of original lot number nineteen (19-92-A, 19-93-A and B, 19-94-A and B, and 19-95) on the official plan and book of reference of the St-Lawrence Ward of the City of Montreal; measuring seventy-seven feet and one inch (77'1\") in width in front on St-Urbain Street and in rear by a depth of one hundred and twenty-three feet (123') English measure and more or less, and all the rights of the emphyteutic lessee under the deed of emphyteutic lease of the said immoveable property executed December 28, 1965 before W.F.W., Pratt, notary, and registered at the Registry Office for the Registration Division of Montreal under number 1882670, as modified by the deed of modification of emphyteutic lease executed March 8, 1966 before W.R.Patterson, notary, and registered at the Registry Office for the Registration Division of Montreal under number 1895319.With the building thereon erected bearing civic number 3605 St-Urbain Street.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the Court House of Montreal.10 Craig Street East, 10th floor.Room 56, on the THIRTEENTH day of June 1975 at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, April 30th 1975.60802-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal I THE MONTREAL CITY No.05-014112-74X 1 AND DISTRICT SAVINGS I BANK, a corporation legally incorporated, having its principal place of business at 266 St.James Street West, Montreal, Judicial District of Montreal, plaintiff, M CHARLES ITZCOVITCH, residing and domiciled at 6600 Kildard Rd., Apt.1208, in Côte Saint-Luc.Judicial District of Montreal, IRVING LEONARD ITZCOVITCH.residing and domiciled at 410 Canterbury Square, in the City of Laval, Judicial District of Montreal, SYDNEY ITZCOVITCH, residing and domiciled at 5604 Westluke Avenue, in Côte-Saint-Luc.Judicial District of Montreal, defendants, and THE REGISTRAR for the Montreal Registration Division, in the City and District of Montreal, mis en cause.\"A certain emplacement fronting on Argyle Avenue, in the City of Verdun, District of Montreal known and designated as being subdivision number one hundred and four of the original lot number four thousand six hundred and seventy-three (4673-104) on the official plan and book of reference of the Parish of Montreal, 3880 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10.1975.Vol.107.No.19 trente pieds de largeur sur cent pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins.Avec la maison et les autres bâtiments y érigés, portant les numéros civiques 609.611 et 613 de ladite avenue Argyle, avec droit de passage en commun avec les autres ayants droit, dans les ruelles attenantes, audits bâtiments.Sous réserve de servitudes réciproques établies et créées pour l'utilité de l'emplacement ci-dessus mentionné et de l'emplacement y attenant, connus comme étant les lots numéro 4673-105 et 4673-ptie 106 dudit cadastre, tel qu'il appert d'un acte en date du septième jour d'octobre, mil neuf cent quarante-six, enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Montréal sous le numéro 669772.Telle que lalite propriété se trouve présentement avec tous ses droits, circonstances et dépendances et sans exception ni réserve d'aucune sorte.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56.le DOUZIÈME jour de JUIN 1975, à ONZE heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du shérif, Paul St-Martin.Cour supérieure, Montréal, le 29 avril 1975.60818 measuring thirty feet in width by one hundred feet in depth, English measure and more or less.With a house and other buildings thereon erected, bearing civic numbers 609, 611 and 613 of said Argyle Avenue, and with right of passage in common with others having rights therein, in the lanes communicating to the said buildings.With and subject to the reciprocal servitudes established and created in favour of the emplacement hereinbefore mentioned and in favour of the emplacement next to it known under lots numbers 4673-105 and 4673-pt.106 of said cadastre as it appears by deed dated the seventh day of October, nineteen hundred and forty-six, registered in the Registry office for the Registration Division of Montreal under number 669772.As the said property now subsists, with all its rights, members and appurtenances, without exception or reserve of any kind.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the Court House of Montreal, 10 Craig Street East.10th Floor, Room 56, on the TWELFTH day of JUNE, 1975, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, April 29.1975.60818-o QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( \\/EZINA, SHEEHAN & Cour Supérieure ) V ASSOCIES, 220 Est, No 200-05-004415-746.) Grande-Allée.Québec, contre [ Mme COLETTE TRUDEL, travaillant à la Clinique Médico Esthétique de Québec, 1481, boulevard St-Cyrille ouest, Québec, et LE RE-GISTRATEUR du bureau d'enregistrement de Québec, mis en cause.« 1.Une partie de la redivision quinze de la subdivision deux cent cinquante-neuf du lot originaire numéro deux cent trois (ptie 203-259-15) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la paroisse de St-Co-lomb-de-Sillery, division d'enregistrement de Québec.Mesurant soixante-cinq pieds (65') au nord-ouest le long de la rue St-Cyrille, cent deux pieds et six dixièmes (102.6') à l'est, trente-neuf pieds et trois dixièmes (39.3') au sud-est.cinquante-trois pieds au sud-ouest, trois pieds (3') au sud-est et quarante-sept pieds au sud-ouest (47'): bornée en front par la rue St-Cyrille, à l'arrière par une partie non subdivisée du lot deux cent trois - deux cent cinquante-neuf, d'un côté par le lot deux cent trois - deux cent quarante-cinq - un, et de l'autre côté par un morceau de terrain étant partie du lot deux cent trois - deux cent cinquante-neuf - seize, et le résidu dudit lot deux cent trois-deux cent cinquante-neuf - quinze, tous du cadastre de St-Colomb-de-Sillcry; 2.Un morceau de terrain formant partie de la indivision seize de la subdivision deux cent cinquante-neuf du lot originaire numéro deux cent trois (203-259-16 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit: ( \\/EZINA, SHEEHAN & Superior Court, J V ASSOCIES, 220 Grande-No.200-05-004415-746.) Allée East, Québec, versus \\ MRS.COLETTE TRUDEL, working at Clinique Médico Esthétique de Québec, 1481 St-Cyrille Boulevard West.Québec, and THE REGISTRAR for the Québec Registry Office, mis en cause.\"1.A part of redivision fifteen of subdivision two hundred fiftynine of original lot number two hundred three (Pt.203-259-15) on the plan and in the book of reference for the official cadastre of the Parish of Saint-Colomb-de-Sillery, Québec Registration Division.Measuring sixty-five feet (65') on the northwest along St-Cyrille Street, one hundred two and six tenths feet (102.6') on the east, thirty-nine and three tenths feet (39.3') on the southeast, fifty-three feet on the southwest, three feet (3') on the southeast and forty-seven feet on the southwest (47'); bounded in front by St-Cyrille Street, in the rear by a non-subdivided part of lot two hundred three - two hundred fifty-nine, on one side by lot two hundred three - two hundred forty-five - one, and on the other side by a piece of land being a part of lot two hundred three - two hundred fifty-nine - sixteen, and the remainder of said lot two hundred three - two hundred fifty-nine - fifteen, all on the cadastre of Saint-Colomb-de-Sillery.2.A piece of land forming part of redivision sixteen of subdivision two hundred fifty-nine of original lot number two hundred three (203-259-16 Pt.) on the plan GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.10mai 1975.107e année.n° 19 3881 ptie) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la paroisse de St-Colomb-de-Sillery, division d'enregistrement de Québec.Borné au nord-ouest par la rue St-Cyrille, au nord-est par le lot deux cent trois - deux cent cinquante-neuf - quinze, au sud-est par le résidu du lot deux cent trois - deux cent cinquante-neuf - seize, et au sud-ouest par le résidu du lot deux cent trois - deux cent cinquante-neuf - seize; mesurant un pied (1') au nord-ouest et quatre pieds (4') au sud-est par une profondeur de quarante-sept pieds (47') sur la ligne sud-ouest et contenant en superficie cent dix-sept pieds carrés et cinq dixièmes (117.5 pi.car.).3.La redivision un de la subdivision deux cent quarante-cinq du lot originaire numéro deux cent trois (203-245-1) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la paroisse de St-Colomb-de-Sillery, division d'enregistrement de Québec.Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, notamment la maison portant le numéro civique 1481, boulevard St-Cyrille ouest, Sillery, Québec.Servitudes Sujet aux servitudes suivantes: a) En faveur de la cité de Sillery, aux termes d'un acte enregistré sous le numéro 342,920; 6) En faveur de Québec Power Company, aux termes d'un acte enregistré sous le numéro 343,097.» Pour être vendus au bureau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, le TREIZIÈME jour du mois de JUIN 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 5 mai 1975.60805-o and in the book of reference of the official cadastre for the Parish of Saint-Colomb-de-Sillery, Québec Registration Division.Bounded on the northwest by St-Cyrille Street, on the northeast by lot two hundred three - two hundred fifty-nine - fifteen, on the southeast by the remainder of lot two hundred three-two hundred fifty-nine-sixteen, and on the southwest by the remainder of lot two hundred three-two hundred fifty-nine - sixteen; measuring one foot (1') on the northwest and four feet (4') on the southeast by a depth of forty-seven feet (47') on the southwest line and covering an area of one hundred seventeen and five tenths square feet (117.5 sq.ft.).3.Redivision one of subdivision two hundred forty-five of original lot number two hundred three (203-245-1) on the plan and in the book of reference of the official cadastre for the Parish of Saint-Colomb-de-Sillery, Québec Registration Division.With the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, namely the house bearing civic number 1481 St-Cyrille Boulevard West, Sillery, Québec.Servitudes Subject to the following servitudes: (a) For the benefit of the City of Sillery, under the terms of a deed registered under number 342,920; (b) For the benefit of Québec Power Company, under the terms of a deed registered under number 343,097.To be sold at the Québec Registry Office, 116 St-Pierre Street, Québec, on the THIRTEENTH day of JUNE, 1975, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec.May 5, 1975.60805 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: [TA VILLE DE QUE-Cour municipale de Québec.) BEC, corporation.No 236 de 1975.) légalement constituée ' ayant son siège social dans les ville et district de Québec, contre JEAN-PAUL DROLET et LOUIS PICHETTE, domiciliés à 1450, des Platanes, et 7149, des Cerfs, Orsainville.district de Québec.\" Un emplacement connu et désigné comme étant le lot numéro trente-trois (33) pour la paroisse de St-Roch-Nord, division d'enregistrement de Québec, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Le tout pour être vendu en bloc en satisfaction du bref de saisie immobilière en cette cause.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice de Québec, 12, rue St-Louis, Quéhec, le TREIZIÈME jour du mois de JUIN 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 5 mai 1975.60804-o Fieri Fadas de Terris Québeè.to wit: ( THE CITY OF QUE- Municipal Court of Québec.J * BEC, corporation No.236 of 1975.) legally incorporated, ' having its head office in the Citv and District of Québec, vs JEAN-PAUL DROLET and IX)UIS PICHETTE, domiciled at 1450 Des Platanes, and 7149 Des Cerfs, Orsainville, District of Québec.\"An emplacement known and described as being lot number thirty-three (33), Parish of Saint-Roch-North, Québec Registration Division, with buildings thereon erected, appurtenances and dependencies.The whole to be sold en bloc in satisfaction of a writ of seizure of immoveable property in this case.\" To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House of Québec.12 Saint-Louis Street, Québec, on the THIRTEENTH day of JUNE, 1975, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, May 5.1975.60804 3882 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 10.1975.Vol.107.No.19 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: (TA CAISSE D'EPARGNE Cour Supérieure ) ET D'ENTRAIDE No 200-05-003638-744.} ECONOMIQUE DE QUE-' BEC, société régie par la Loi des caisses d'épargne et de crédit, ayant siège social à 229 est, boul.Cliarest, Québec vs SOGLM LTEE, corps politique légalement constitué, ayant son siège social au 360, boul.Cliarest est, Québec.« La subdivision deux du lot originaire mille quatre-vingt-treize (1093-2) du cadastre officiel pour le quartier de Jacques Cartier, division d'enregistrement de Québec; le lot originaire numéro mille quatre-vingt-quatorze du susdit cadastre (1094) la subdivision un du lot originaire mille cent trois (1103-1) du susdit cadastre.Tel que le tout actuellement avec maison dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau du shérif.Palais de justice, 12 rue St-Louis, Québec, le TREIZIÈME jour de JUIN 1975 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif J.Roland Renault.Québec, le 5 mai 1975.60803-o Fieri Facias de'Terris Québec, to wit : (TA CAISSE D'EPARGNE Superior Court, ) *-> ET D'ENTRAIDE No.200-05-003638-744.j ECONOMIQUE DE QUE-( BEC, a corporation governed by the Savings and Credit Unions Act, having its head office at 229 Charest Boulevard East, Québec, vs SOGIM LTEE, a body politic legally incorporated, having its head office at 360 Charest Boulevard East, Québec.\"Subdivision number two of original lot number one thousand ninety-three (1093-2) on the official cadastre for Jacques Cartier Ward, Québec Registration Division; original lot number one thousand ninety-four on the aforesaid cadastre (1094) ; subdivision number one o original 1 ot number one thousand one hundred and three (1103) on the aforesaid cadastre.As the whole now subsists, with the house erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House, 12 St-Louis Street, Québec, on the THIRTEENTH day of JUNE, 1975, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office Assistant Sheriff.Québec, May 5, 1975.60803 RIMOUSKI Fieri Facial de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale (Matane) \u2014 District de Rimouski ( OÉVÉR1N PELLETIER, do-Dossier no: M-2285.) *J micilié à Matane, district de \\ Rimouski.demandeur, vs DE-l NISBÉRUBÉ, domicilié à Cap-Chat, comté de Matane.défendeur.Les lots numéros vingt-trois-C-1 (23-C-l) et vingt-trois-D-1 (23-D-l) du lang 1 du cadastre officiel revisé du Canton Romieux avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendus au Bureau d'enregistrement, division de Matane, en la ville de Matane, le DIXIÈME jour de JUIN 1975, à QUATORZE heures.Le shérif adjoint.Bureau du shérif, Bertrand Doyon.Rimouski, le 29 avril 1975.60817-o RIMOUSKI Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court (Matane) \u2014 District of Rimouski iCÉVÉRIN PELLETIER, domi-»-> ciled in Matane, District of Rimouski, plaintiff, vs DENIS BÈ-RUBÉ, domiciled in Cap-Chat, County of Matane, defendant.Lots numbers twenty-three C-l (23-C-l) and twenty-three D-l (23-D-l) in Range 1 of the revised official cadastre of the Township of Romieux, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.To be sold at the Matane Division Registrv Office in the Town of Matane, on the TENTH day of JUNE, 1975, at TWO o'clock in the afternoon.Bertrand Doyon, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Rimouski, April 29, 1975.60817 SAINT-HYACINTHE S A I N T - H Y A C I N T H E Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de St-Hyacinthe ( f~* HARTER CREDIT COR-No 750-05-000279-74.< ^ PORATION.demande-l resse, vs SANAIR INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Bagot, mis en cause.L'immeuble ci-après désigné, en la possession de la défenderesse: Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Saint-Hyacinthe (riHARTER CREDIT No.750-05-000279-74.< V-/ CORPORATION, plaintiff, vs SANAIR INC., de-fendant, THE REGISTRAR for the Bagot Registration Division, mis en cause.The immoveable hereinafter described, owned by the defendant: GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC.10mai 1975.107e année, n\" 19 Annexe « A » Celte propriété étant une partie du lot cent quatre-vingt-sept (P.187).le lot cent quatre-vingt-onze (191).une partie des lots cent quatre-vingt-quatorze (P.194).cent quatre-vingt-quinze (P.195) et cent quatre-vingt-seize (P.196) au cadastre de la paroisse de Saint-Pie.division d'enregistrement de Bagot.peut être plus particulièrement décrite comme suit : 1.Description : Il Parcelle « I, 2, 3,4 ».partie du lot 187 : Commençant au point .1 » du plan ci-joint, lequel point est situé à l'intersection des lots 187.191 et 188.Du point
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.