Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1 septembre 1917, samedi 1 (no 35)
[" Gazette Officielle de Québec PUBLIEE PAR AUTORITÉ Quebec Official Gazette PUBLISHED\tBY AUTHORITY PROVINCE DE QUÉBEC\tPROVINCE OF QUEBEC Québec, samedi, 1er septbmbre 1917.\tQuebec, Saturday, 1st September, 1917.Nomination\tAppointment Il a plu à Son Honneur le lieutenant-gouverneur, His Honour the Lieutenant Governor has been de l'avis et du consentement du Conseil exécutif, pleased, by and with the advice and consent of the de faire les nominations suivantes: Executive Council, to make the following ap- Québec, 8 août 1917.pointments: M.Armand Boisseau, de Saint-Hyacinthe, Quebec, 8th August, 1917.notaire, greffier de la cour du magistrat, à Saint- Armand Boisseau, notary, of Saint Hyacinthe, Hyacinthe.' 3963 clerk of the magistrate's Court, at Saint Hyacinthe.3964 Arrêtés ministériels Orders-in-Council CONSEIL EXECUTIF.EXECUTIVE COUNCIL.Québec, 23 août 1917.Quebec, 23rd August, 1917.Présent: Le lieutenant-gouverneur en Conseil.Present: The Lieutenant Governor in Council.Attendu qu'une résolution passée par le conseil Whereas by resolution passed by the municipal municipal de la paroisse de Saint-Hubert, dans le council of the parish of Saint Hubert, in the coun- comté de Témiscouata, le sixième jour d'août, ty ot Temiscouata, on the sixth day of August, 1917, a fait voir à Son Honneur le lieutenant-gou- 1917, it hath been shewn to His Honour the verneur que la publication de tout avis, règle- Lieutenant-Governor that the puolication of any ment ou résolution dudit conseil municipal à être notice, by-law or resolution of the said municipal fait en vertu du code municipal de la province council to be made under the provisions of the 1936 de Québec;, pourm se faire dans la langue française seulement, sans préjudice pour aucuns des habitants de ladite municipalité; et attendu que toutes les formalités de la loi ont été remplies; Il est ordonné que les avis, règlements et résolutions dudit conseil municipal de la paroisse de Saint-Hubert, dans le comté de Témiscouata, dont la publication est prescrite par les dispositions du code municipal de la province de Québec se publient il l'avenir dans la langue française seulement.lie greffier du Conseil exécutif, A.MORISSET.Publié en conformité de l'article 130 du code municipal de la province de Québec.Le sous-secrétaire de la province, 3955 C.-J.SIMARD.said Municipal Code of the Province of Quebec, may be so made in the French language only, without detriment to any of the inhabitants ot said municipality; and whereas all the formalities required by law have been observed; It is ordered that the notices, by-laws and resolutions oi the said municipal council of the parish of Saint Hubert, in the county of Témiscouata, the publication of which is required by the provisions of the Municipal Code of the Province of Quebec be henceforth published in the French language onlv.A.MORISSET, Clerk Executive Council.Published in conformity with article 130 of the Municipal Code of the Province of Quebec.C.-J.SIMARD, 3956 Assistant Provincial Secretary.Québec, 23 août 1917.Quebec;.23rd August, 1917.Présent: Le lieutenant-gouverneur en Conseil.Present: The Lieutenant Governor in Council.Attendu qu'une résolution passée pai le conseil municipal de la partie ouest du canton Port-Daniel, dans le comté de Bona venture, le quatrième jour de juin, 1917 a fait voir à Son Honneur le lieutenant-gouverneur que la publication de tout avis, règlement ou résolution dudit conseil municipal à être fait en vertu du code municipal de la province de Québec, pourra se faire dans la langue anglaise seulement, sans préjudice pour aucuns des habitants de ladite municipalité; et attendu que toutes les formalités de la loi ont été remplies; Il est ordonné que les avis, règlements et résolutions dudit conseil municipal de la partie ouest du canton Port-Daniel, dans le comté de Bona venture, dont la publication est prescrite par les dispositions du code municipal de la province de Québec se publient à l'avenir dans la langue anglaise seulement.Le greffier du Conseil exécutif, A.MORISSET.Publié en conformité de l'article 130 du code municipal de la province de Québec.Le sous-secrétaire \u2022 de la province, 3957 C.-J.SIMARD.Whereas by resolution passed by the municipal council of the west part of the township ot Port-Daniel, in the county of Bona venture, on the fourth day of June, 1917, it bath been shewn to His Honour the Lieutenant Governor that the publication of any notice, by-law or resolution oi the said municipal council to be made under the provisions ot the said Municipal Code of the Province of Quebec, may be so made in the English language only, without detriment to any of the inhabitants of said municipality; and whereas all the formalities required by law have been observed; It is ordered that the notices, by-laws and resolutions of the said municipal council of the west part ot the township of Port-Daniel, in the county of Bonaventure, the publication of which is required by the provisions of the Municipal Code of the province of Québec be henceforth published in the English language only.A.MORISSET, Clerk Executive Council.Published in conformity with article 130 of the Municipal Cpde of the Province of Quebec.C.-J.SIMARD, 3958 Assistant Provincial Secretary.Québec, 23 août 1917.Quebec, 23rd August, 1917.Présent: Le lieutenant-gouverneur en Conseil.Present: The Lieutenant Governor in Council.Attendu qu'une résolution passée par le conseil municipal de la paroisse de Saint-Benoit, dans le comté de Deux-Montagnes, le sixième jour d'août 1917, a fait voir à Son Honneur le lieutenant-gouverneur que la publication de tout avis, règlement ou résolution dudit conseil municipal à être fait en vertu du code municipal de la province de Québec, pourra se faire dans la langue française seulement, sans préjudice pour aucuns des habitants de ladite municipalité; et attendu que toutes les formalités de la loi ont été remplies ; Il est ordonné que les avis, règlements et résolutions dudit conseil municipal de la paroisse de Saint-Benoit, dans le comté de Deux-Montagnes, dont la publication est prescrite par les dispositions du code municipal de la province de Québec, se publient à l'avenir dans la langue française seulement.Le greffier du Conseil exécutif, A.MORISSET.Publié en conformité de l'article 130 du code municipal de la province de Québec.Le sous-secrétaire de la province, 3959 C.-J.SIMARD.Whereas by resolution passed by the municipal council of the parish of Saint-Benoit, in the county of Two Mountains, on the sixth day of August, 1917, it bath been shewn to His Honour the Lieutenant Governor that the publication oi any notice, by-law or resolution of the said municipal council to be made under the provisions of the said Municipal Code of the Province of Quebec, may be so made in the French language only, without detriment ti any ot the inhabitants of said municipality; and whereas .11 the formalities required by law have been observed; It is ordered that the notices, by-laws and resolutions of the said municipal count il of the parish of Saint Benoit, in the county of Two Mountains, the publication ot which is required by the provisions of the Municipal Code of the Province of Quebec, be henceforth published in the French language only.A.MORISSET, Clerk Executive Council.Published in conformity with article 30 of the Municipal Code of the Province of Quebec.C.J.SIMARD, 3960 Assistant Provincial Secretary. 1937 Proclamations Proclamations Canada, Province de P.-E.LEBLANC.Québec.[L.S.j GEORGE V, par la Grâce de Dieu, Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers.Défenseur de la Foi, Empereur des Indes, A tous ceux qui ces présentes verront ou qu'elles I>euvent concerner,\u2014Salut: PROCLAMATION.LomehGouin, \\ ATTENDU que J.-A.Procureur-Général.! Lemire, secrétaire des commissaires dûment nommés pour les fins du chapitre premier du titre neuf des Statuts refondus de la province de Québec, dans et pour le diocèse catholique romain de Trois-Rivières, dans Notre province de Québec, tel que canoni-quement reconnu et érigé par les autorités ecclésiastiques, a, sous l'autorité des dits statuts, transmis au Lieutenant-Gouverneur de Notre dite province de Québec, sou certificat constatant qu'il n'a été déposé à son bureau aucune opposition à la reconnaissance du décret canonique de l'autorité ecclésiastique du dit diocèse et aussi le dit décret canonique dans lequel sont décrites et déterminées les limites et bornes qu'ils ont cru le plus convenable d'assigner à la paroisse de Sainte-Angèle, dans le comté de Maski-nongé, dans le dit diocèse susdit, comme suit, savoir : Le territoire à être érigé en paroisse civile sous le nom de \"La paroisse de Sainte-Angèle\", dans le comté de Maskinongé, est formé de démembrements des paroisses de Saint-Paulin et de Sainte-Ursule, et comprend : 1.Du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Paulin, les lots numéros depuis y compris 396 jusqu'à 442 inclus, dans la concession Waterloo.2.Du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Ursule, les lots numéros: de 98 à 124 inclus, dans la concession Grand-Pré ou New Waterloo, de 79 à 97 inclus, dans la concession Grand-Pré ou Philibert, de 125 à 135 inclus, dans la concession Augusta ; le lot No 252 dans la concession Terre-neuve, et enfin tous les lots des premier et second rangs du gore de Hunterstown, ainsi que ceux du gore Hunterstown lui-même.Le territoire, ainsi formé des lots ci-dessus énumérés, cocupe une étendue d'environ 7217 arpents carrés en superficie, dont 5600 arpents proviennent de la paroisse de Sainte-Ursule, et 1017 de la paroisse de Saint-Paulin, le tout plus ou moins.A CES CAUSES, Nous avons confirmé, établi et reconnu, et par les présentes confirmons, établissons et reconnaissons les limites et bornes de la paroisse de Sainte-Angèle ci-dessus décrites; Et Nous avons ordonné et déclaré, et par les présentes ordonnons et déclarons que la paroisse de Sainte-Angèle, décrite comme susdit, sera une paroisse pour toutes les fins civiles en conformité des dispositions des susdits Statuts.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes pourront concerner, sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En Foi de Quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelies Canada, Province of P.-E.LEBLANC.Quebec.[L.S.] GEORGE THE FIFTH, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and of the British Dominions beyond the Seas, King, Defender of the Faith, Emperor of India.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern,\u2014Greeting: PROCLAMATION.Lomer Gouin, i \"W7HEREAS j.-A.Lemire, Attorney General.) »V the secretary to the duly appointed Commissioners for the purposes of chapter first of title nine of the Revised Statutes of the province of Quebec, in and for the Roman Catholic Diocese of Three Rivers, in Our Province of Quebec, canonically acknowledged and erected by the Ecclesiastical authorities, has, under the authority of the said Statutes transmitted to the Lieutenant-Governor of Our said Province of Quebec, his certificate establishing that no opposition lias been made to the civil recognition of the canonical decree of the Ecclesiastical authorities together with the canonical decree, by which they describe and declare the limits and boundaries which they think most expedient to be assigned to the parish of Sainte-Angèle, in the county of Maskinongé, in the said Roman Catholic Diocese of Three Rivers, to be as follows, that is to say: The territory to be erected into a civil parish under the name of \"The parish of Sainte-Angèle\", in the county of Maskinongé, is formed of dismemberments of the parishes of Saint-Paulin and of Sainte Ursule and comprises:\u2014 1.Of the official cadastre of the parish of Saint Paulin, the lots numbers 396 to 442, both inclusive in the Waterloo concession.2.Of the official cadastre of the parish of Sainte-Ursule, the lots numbers: 98 to 124, both inclusive, of the Grand-Pré or New Waterloo concession, 79 to 97, both inclusive, in the Grand Pré or Philibert concession, 125 to 155, both inclusive, in the Augusta concession; the lot No.252 in the Terreneuve Concession, and finally all the lots of the first and second ranges of the gore of Hunterstown together with those of the gore of Hunterstown itself.The territory thus formed of the above described lots, covers a superficial area of about 7217 arpents, of which 5600 arpents are detached from the parish of Sainte Ursule and 1617 from the parish of Saint Paulin, the whole more or less.NOW KNOW KE, that we have confirmed, established and recognised and by these presents do confirm, establish and recognise the aforesaid limits and boundaries of the parish of Sainte-Angèle, aforesaid; And We have erected and declared and by these presents erect and declare the said parish of Sainte-Angèle, to be a parish for all civic purposes, agreeably to the provisions of the aforesaid Statutes.Of all which Our loving subjects, and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony Whereof, We have caused these our Letters to be made Patent, and 1938 apposer le grand sceau de Notre province de Québec.Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Sir PIERRE-EVARISTE LEBLANC, chevalier, commandeur de Notre ordre très distingué de Saint-Michel et de Saint-Georges, lieutenant-gouverneur de notre province de Québec.Donné en Notre Hôtel du Gouvernement, à QUEBEC, ce VINGT-HUITIEME jour du mois d'AOUT, l'an de grâce mil neuf cent dix-sept et de Notre rèfcne le huitième.Par ordre, Le sous-secrétaire de la province, 3993 C.-J.SIMARD.the Great Seal of Our said Province of Quebec to be hereunto affixed, Witness : Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable Sir PIERRE-EVA-RISTE LEBLANC, Knight, Commander of Our Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George, Lieutenant Governor of our said Province.At Our Government House, in Our City of QUEBEC, this TWENTY EIGHTH day of the month of AUGUST, in the Year of Our Ix>rd, one thousand nine hundred and seventeen, and in the eighth year of Our Reign.By command, C.-J.SIMARD, 3994 Assistant Provincial Secretary.Canada, Province de P.-E.LEBLANC.Québec.[L.S.1 GEORGE V, par la Grâce de Dieu, Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers.Défenseur de la Foi, Empereur des Indes.A tous ceux qui ces présentes verront ou qu'elles peuvent concerner\u2014Salut : PROCLAMATION.Canada, Province of Quebec.L.S.] GEORGE V, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and of the British Dominions beyond the Seas, King, Defender of the Faith, Emperor of India.To all to whom these presents sliall come or whom the same may concern,\u2014Greeting : PROCLAMATION Lomer Gouin, \"I ATTENDU qu'en vertu Procureur-général.J des dispositions du code municipal de la province de Québec, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par une proclamation publiée dans la Gazette officielle de Québec, laquelle entrera en vigueur à la date y mentionnée, ordonner l'érection de municipalités de village ou de campagne, la division de ces municipalités ou leur annexion en tout ou en partie, à d'autres municipalités, môme de cité, de ville ou de village, dans un seul et même comté, ou encore ordonner le changement des limites de celles déià existantes, pourvu que ce soit à la requête de la majorité des propriétaires des biens-fonds compris dans les limites du territoire dont l'érection en municipalité ou la division ou l'annexion à une municipalité est demandée et pourvu aussi qu'après tel changement, chaque municipalité conserve, selon le cas, la population ou le nombre d'habitations requis par la loi ; Attendu qu'une requête signée par la majorité des propriétaires des biens-fonds compris dans un certain territoire ci-après décrit et situé dans la municipalité de Saint-Simon de la Baie Ha! Ha! comté de Rimouski, Nous a été présentée, demandant de détacher ce territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Simon de la Baie Ha! Ha! comté de Rimouski et de l'annexer à la municipalité de la paroisse de Saint-Mathieu de Rioux, dans le dit comté de Rimouski.Attendu qu'il Nous a été démontré que ce territoire contient une population de trois cents âmes, et qu'après son érection en municipalité séparée, il restera dans la municipalité d'où ce territoire a été détaché, une population de trois cents âmes ; Attendu qu'il Nous a été démontré que la description technique de ce territoire fait selon les exigences de la loi et figurant le territoire dont on demande l'annexion à la municipalité de la Lomer Gouin, \\ TY7HEREAS in and by Attorney-General./ virtue of the provi- sions of the Municipal Code of the Province of Quebec, the Lieutenant Governor in council may, by proclamation, published in the Quebec Official Gazette, which shall come into force on the date therein mentioned, order the erection of village or rural municipalities, the division oi such municipalities or their annexation in whole or in part to other municipalities, whether of cities, towns or villages, in one and the same county, or also order the alteration of the boundaries of those already existing, provided that application to that effect be made by the majority of the proprietors of immoveable property situated within the limits of the territory whereof the erection into a municipality, or the division, or the annexation to a municipality, is applied for, and provided also that, after such change, each municipality still possesses, as the case may be, the population or the number of inhabited houses required by law ; Whereas, a petition signed by the majority of the proprietors of immoveable property comprised within that certain territory hereinafter described and situated in the municipality of Saint Simon de la Baie Ha! Ha! county of Rimouski has been presented to Us, making application to detach this territory from the municipality of the parish of Saint Simon de la Baie Ha! Ha!, county of Rimouski, and to annex it to the municipality of Saint Mathieu de Rioux, in the county of Rimouski; Whereas, it hath been shewn to Us that his territory contains a population of three hundred souls and that after its erection into a distinct municipality there shall still remain in the municipality from which this territory has been detached, a population of three Jiundred souls ; Whereas, it hath also been shewn to Us that the technical description of this territory made according to the requirements of law, and showing the territory sought to be annexed to the 1939 paroisse dc#Saint-Mathieu de Rioux, a été approuvée par Notre Ministre des Terres et Forêts.Attendu que toutes les autres formalités de la loi ont été remplies et qu'en conséquence, Nous avons jugé à propos de faire droit à la requête qui Nous a été présentée ; A CES CAUSES, du consentement et de l'avis de Notre conseil exécutif, et conformément aux dispositions du code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons par les présentes que ledit territoire savoir : Tout le territoire borné comme suit : \\je territoire devant être annexé à la municipalité de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Rioux, dans le comté de Rimouski, est détaché de la municipalité de la paroisse de Saint-Simon-de-la-Baie-Ha!-Ha! et comprend: Les lots numéros deux cent quatre-vingt-huit (288), deux cent quatre-vingt-dix (290), deux cent quatre-vingt-treize (293), deux cent quatre-vingt-quatorze (294), deux cent quatre-vingt-dix-sept (297), deux cent quatre-vingt-dix-huit (298), du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Simon-de-la-Baie-Ha!-Ha!, et la partie comprise entre la rivière de la déchage du lac et la ligne limitative des deux paroisses sus-nommées, de chacun des lots numéros deux cent soixante-dix-sept (277), deux cent soixante-dix-huit (278).deux cent soixante-dix-neuf (279), deux cent quatre-vingt (280).deux cent quatre-vingt-un (281), deux cent quatre vingt-trois (283), deux cent quatre-vingt-quatre (284), deux cent quatre-vingt-cinq (285), deux cent quatre-vingt-six (280), deux cent quatre-vingt-sept (287), du cadastre susdit de la paroisse de Saint-Simon-de-la-Baie-Ha!-Ha!, le tout étant situé dans le deuxième rang de la seigneurie de Nicolas Rioux, sera détaché de la municipalité de la paroisse de Sabit-Simon-de-la-Baie-Ha!-Ha! et annexé à la municipalité de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Rioux, à partir de ce jour.De tout ce que dessus, tous nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner, sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En Foi de Quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles fait apposer le grand sceau de Notre province de Québec.Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Sir PIERRE-EVARISTE LEBLANC, chevalier, commandeur de Notre ordre très distingué de Saint-Michel et de Saint-Georges, lieutenant-gouverneur de notre province de Québec.En l'Hôtel du Gouvernement, de Notre province de QUEBEC, ce VINGT-NEUVIEME jourd'AOUT en l'année mil neuf cent dix-sept de l'ère chrétienne et de Notre règne la huitième année.Par ordre, Le sous-secrétaire de la province, 3995 C.-J.SIMARD.municipality of the parish of Saint Mathieu de Rioux, has been approved by Our Minister of Lands and Forests- Whereas all the other requirements of law have been fulfilled and that in consequence, We have deemed fit to comply with the petition presented to Us ; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, and pursuant to the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We declare, by these presents, that the said territory, viz : All the territory bounded as follows : The territory to be annexed to the municipality of the parish of Salnt-Mathieu-de-Rioux, in the county of Rimouski, is detached from the municipality of the parish of Saint-Simon-de-la-Baie-Ha!-Ha! and comprises: The lots numl>er two hundred and eighty eight (288), two hundred and ninety (290), two hundred and ninety three (293), two hundred juid ninety four (294), two hundred and ninety seven (297), two hundred and ninety eight (298) of the officiel cadastre of the parish of Saint-Simon-de-la-Baie-IIa!-Ha!, and the part comprised between the rivière de la décharge du lac and the division line of the two aforementioned parishes, of each of the lots numbers two hundred and seventy seven (277) two hundred and seventy eight (278), two hundred and seventy nine (279), two hundred and eighty (280), two hundred and eighty one (281), two hundred and eighty three (283), two hundred and eighty four (284), two hundred and eighty five (285), two hundred and eighty six (280), two hundred and eighty seven (287), of the aforesaid cadastre of the parish of Saint-Simon-de-la-Baie-Ha!-Ha!, the whole being situate in the second range of the seigniory of Nicolas Rioux, shall be detached from the municipality of the parish of Saint-Simon-de-la-B ie-Ha!-Ha! and shall henceforth be annexed to the parish Saint-Mathieu-de-Rioux.Af All which Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and govern themselves accordingly.In Testimony Whereof, We have caused these our Letters to be made Patent,and the Great Seal of Our said Province of Quebec to be hereunto affixed : Witness Our Right Trusty and Well Beloved The Honourable Sir PIERRE-EVARISTE LEBLANC, Knight, Commander of Our Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George, Lieutenant Governor of Our said Province.At Our Government House, in Our City of QUEBEC, this TWENTY NINE day of AUGUST in the Year of Our Lord one thousand nine hundred and seventeen, and in the eight year of Our Reign.By command, C.-J.SIMARD, 3996 Assistant Provincial Secretary.P.-E.LEBLANC.Canada, Province de Québec.[L.S.] GEORGE V, par la Grâce de Dieu, Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Défenseur de la Foi, Empereur des Indes.P.-E.LEBLANC.Canada, Province of Quebec.[L.S.] GEORGE V, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and of the British Dominions beyond the Seas, King, Defender of the Faith, Emperor of India. 1940 A tous ceux qui ces présentes verront ou qu'elles peuvent concerner\u2014Salut.PROCLAMATION.Lomer Gouin, \\ A TTENDUqu'en ProcureurJjénéral.) vertu des dispositions du code municipal de la province de Québec, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par une proclamation publiée dans la Gazette officielle de Québec, laquelle entrera en vigueur à la date y mentionnée, ordonner l'érection de municipalités de village ou de campagne, la division de ces municipalités ou leur annexion en tout ou en partie, à d'autres municipalités, même de cité, de ville ou de village, dans un seul et même comté, ou encore ordonner le changement des limites de celles déjà existantes, pourvu que ce soit à la requête de la majorité des propriétaires des biens-fonds compris dans les limites du territoire dont l'érection en municipalité ou la division ou l'annexion à une municipalitée est demandée et pourvu aussi qu'après tel changement, chaque municipalité conserve, selon le cas, la population ou le nombre d'habitations requis par la loi; Attendu qu'une requête signée par la majorité des propriétaires des biens-fonds compris dans un certain territoire situé dans la municipalité de Wickham Ouest, comté de Drummond, Nous a été présentée, demandant de détacher ce territoire de la municipalité de Wickham Ouest et de l'annexer à la municipalité de la paroisse de Saint-Germain de Grantham, comté de Drummond; Attendu qu'il Nous a été démontré qu'il restera aans la municipalité d'où ce territoire a été détaché, une population de trois cents âmes; Attendu qu'il Nous a été démontré que la description technique de ce territoire fait selon les exigences de la loi et figurant le territoire dont on demande l'annexion à la mumicipalité de la paroisse de Saint-Germain de Grantham, a été approuvé par Notre Ministre des Terres et Forêts; Attendu que toutes les autres formalités de la loi ont été remplies et qu'en conséquence, Nous avons jugé à propos de faire droit à la requête qui Nous a été présentée; A CES CAUSES, du consentement et de l'avis de Notre conseil exécutif, et conformément aux dispositions du code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons par les présentes que le dit territoire, savoir: Tout le territoire borné comme suit : Le territoire devant être détaché de la municipalité de Wickham-Ouest, dans le comté de Drummond, pour être annexé à la municipalité de la paroisse de Saint-Germain-de-Grantham, comprend: Les lots numéros quatre cent quarante-six (446) quatre cent quarante-sept (447) et quatre cent quarante-huit (448) du cadastre officiel du cadastre officiel du canton Wickham.correspon-dant respectivement aux moitiés nord-ouest et sud-est du lot numéro vingt-huit (28) ou à la moitié nord-ouest du lot numéro vingt-sept (27) de la subdivision primitive du neuvième rang du canton Wickham sudit, dans le comté Drummond, sera détaché de la municipalité de Wickham-Ouest et annexé à la municipalité de la paroisse de Saint-Germain-de-Grantham, à partir de ce jour.De tout ce que dessus tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner, sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern,\u2014Greeting: PROCLAMATION.Lomer Gouin, \\ \\Y/HEREASmAud Attorney-General./ VV by virtue of the provisions of the Municipal Code of the Province of Quebec, the Lieutenant-Governor-in-Council may, by proclamation, published in the Quebec Official Gazette, which shall come into force on the date therein mentioned, order the erection of village or rural municipalities, the division of such municipalities or their annexation, in whole or in part, to other municipalities, whether of cities, towns or villages, in one and the same county, or also order the alteration of the boundaries of those already existing, provided that application to that effect be made by the majority of the proprietors of immoveable property situated within the limits of the territory whereof the erection into a municipality or the division, or the annexation to a municipality, is applied for, and provided also that, after such change, each municipality still possesses, as the case may be, the population or the number of inhabited housei required by law; Whereas a petition signed by the majority of the proprietors of the immoveable property comprised within that certain territory hereinafter described and situated in the municipality of Wickham West, county of Drummond, has been presented to Us, making application to detach thi3 territory from the municipality of Wickham ouest and to annex it to the municipality of Saint Germain de Grantham, county of Drummond.Whereas it hath been shewn to Us that there shall still remain in the municipality from which this territory has been detached, a population of three hundred souls ; , Where as it liath also been shewn to Us that the technical description of this territory made according to the requirements of the law, and showing the territory sought to be annexed the municipality of the parish of Saint Germain de Grantham, has been approved by Our Minister of Lands and Forests ; Whereas all the other requirements of the law have been fulfilled and that in consequence We have deemed fit to comply with the petition presented to Us; THEREFORE, that by and with the advice and consent of Our Executive Council, and pursuant to the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We declare by the«e presents, that the said territory, viz: All the territory bounded as follows: The territory to be detached from the municipality of Wickham West, in the County of Drummond and annexed to the municipality of the parish of Saint-Germain de-Grantham, comprised: The lots numbers four hundred and forty six (446), four hundred and forty seven (447) and four hundred and forty eight (448) of the official cadastre of Wickham township, corresponding respectively to the north west and southeast halves of the lot number twenty eight (28) and to the north west half of the lot number twenty seven (27) of the original subdivision of the ninth range of the aforesaid Wickham township, in the County of Drummond.shall be detached from the municipality of Wickham West and annexed to the municipality of the parish of Saint Germain de Grantham.Of all which Our loving subjects, and all others whom these présente may concern art hereby required to take notice and to govern themselves accordingly. 1941 En Foi de Quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles fait apposer le grand sceau de Notre province de Québec.Témoin: Notre très fidèle et bien aimé l'honorable Sir PIERRE-EVAR1STE LEBLANC, chevalier, commandeur de Notre ordre tiès distingué de Saint-Michel et de Saint-Georges, lieutenant-gouverneur de notre province de Quéliec.En l'Hôtel du Gouvernement, de Notre province de QUEBEC, ce VINGT-HUITIEME jour d'AOUT en l'année mil neuf cent-dix-sept de l'ère chrétienne et de Notre règne la huitième année.Par ordre, Le sous-secrétairc de la province, 3997 C.-J.SIMARD.Canada, Province de P.-E.LEBLANC Québec.L.S.GEORGE V, par la grâce de Dieu, Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Défenseur de la foi, empereur des Indes:\u2014 A tous ceux qui ces présentes verront ou qu'elles peuvent concerner\u2014Salut: PROCLAMATION LomerGouin, ) ATTENDU que Procureur Général.} par le paragra- phe onze de la section trente-quatre, du chapitre premier des Statuts revisés du Canada, 1906, il est décrété que le premier lundi de septembre sera à l'avenir un jour non juridique, connu sous le nom de FETE DU TRAVAIL.Et attendu qu'il est à propos que le dit premier lundi de septembre soit déclaré jour non juridique dans notre province de Québec.A CES CAUSES, par et de l'avis de Notre conseil exécutif de Notre province de Québec, Nous avons réglé et ordonné, et, par les présentes réglons et ordonnons que le LUNDI, le TROIZIEME jour de SEPTEMBRE prochain (1917), est et sera considéré jour non juridique comme fête du travail dans Notre dite province de Québec.De tout ce que dessus tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes pourront concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En Foi de Quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles fait apposer le grand sceau de Notre province de Québec.Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Sir PIERRE-EVARISTE LEBLANC, chevalier, commandeur de Notre ordre très distingué de Saint-Michel et de Saint-Georges, lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre Hôtol du Gouvernement, à QUÉBEC, ce VINGT-QUATRIÈME jour de SEPTEMBRE, l'an de grâce mil neuf cent dix-sept et de Notre règne le huitième.Par ordre, Le sous-secrétaire de la province.3913 C.J.SIMARD, In testimony whereof, We have caused these Our Iietters to be made Patent and the Great Seal of the Province of Quebec, to lie hereunto affixed.Witness : Our Bight Trusty and Well Beloved the Honourable Sir PIERRE-EVARISTE LEBLANC, Knight, Commander of Our Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George, Lieutenant-Governor of Our said Province.At Our Government House, in Our City of QUEBEC, this TWENTY EIGHTH day of AUGUST, in the Year of Our Lord one thousand nine hundred and seventeen, and in the eighth year of Our Reign.Bv command, C.:J.SIMARD, 3998 Assistant Provincial Secretary.Canada, Province of P.-E.LEBLANC Quebec.L.S.GEORGE THE FIFTH, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and of the British Dominions beyond the Seas, King, Defender of the Faith, Emperor of India, To all to whom these presents shall come or whom the same may concern\u2014Greeting: PROCLAMATION Lomer Gouin, | VA/HEREAS by pa-Attorney General.j V V ragraph eleventh section thirty fourth, of the first chapter of the revised Statutes of Canada, 1906, it is enacted that the first Monday of September shall in future be a non juridical day, known under the name of LABOR DAY.And whereas it is proper that the said first Monday of September be declared a non juridical day in Our said province of Quebec.NOW KNOW YE, that by and with the advice and consent of the Executive counc ilof Our Province of Quebec We have enacted and ordered, and do hereby, enact and order, that MONDAY, the THIRD day of SEPTEMBER next (1917), is and shall be a non-juridical day as labor day, in Our said Province of Quebec.Of all which Our loving subjects, and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In Testimony Whereof, We have caused these our Letters to be made Patent, and the Great Seal of Our said Province of Quebec, to be hereunto affixed: Witness Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable Sir PIERRE EVARISTE LEBLANC, Knight, Commander of Our Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George, Lieutenant Governor of Our Province of Quebec.At Out Government House, in Our City of QUEBEC, this TWENTY-FOURTH day of the month of SEPTEMBER in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and seventeen, and in the eighth year of Our Reign.By command, C.J.SIMARD, 3914 Deputy Provincial Secretary. 1942 Lettres patentes Letters patent \"|The Canadian Skirt & Waist Manufac- \" The Canadian Skirt & Waist Manufacturing Company, Limited\".turing Company, Limited\".Avis est donné au public que, en vertu de la loi Public notice is hlereby given that, under the des compagnies de Québec, il a été accordé par le Quebec Companies' Act, letters patent have been lieutenant-gouverneur de la province de Québec, issued by the Lieutenant-Governor of the pro- des lettres-patentes, en date du vingt-troisième vince of Quebec, bearing date the twenty third jour d'août 1917, constituant en corporation day of August, 1917, incorporating M.M.Isidore M.M.Isidore Popliger, avocat, Ovila Desroches, Popliger, advocate, Ovila Desroches, bailiff, huissier, Moses Kunin, de Montréal, Harry Moses Kunin, merchant, Montreal, Harry Hopmyer, marchand, de la ville de Saint-Pierre Hopmyer, merchant, of the town of Saint Pierre et Antoine Gougeon, mécanicien, pour les fins and Antoine Gougeon, mechanic, of Montreal, for suivantes: the following purposes : Exercer le commerce de manufacturiers, impor- To carry on the business of manufacturers, tateurs, exportateurs et marchands d'accoutre- importers, exporters and dealers in ladies wares ments d'aucune nature et description, pour dames; of any kind and description ; to deal in dry goods, faire le commerce de nouveautés, des soies, satins, silks, sateens, linings and triiimungs, textiles of doublures et garnitures, tissus de toutes es^ces, every kind, cloth, woollen and cotton goods and des articles en drap, laine et coton ainsi que other wears, and also to carry on the business of des autres vêtements, exercer aussi le commerce dealers, clothiers, and jobbers ; de marcliands, drapiers et \"jobbers\"; Exercer aucun autre commerce semblable, de To carry on any other similar business manu-fabrication ou autre, se rattachant aux objets facturing or otherwise, incidental of the above précités, que la compagnie jugera susceptible objects, and which may appear to the company d'être profitablement exercé en rapport avec le capable of being carried on profitably in connec- commerce ci-biiut ; tion with any of the foregoing business ; Représenter les fabricants pour la vente de To represent manufacturers for all ladies tous vêtements pour dames, des articles de wears, and dry goods, or other specialities on nouveautés ou autres spécialités, à commission, commission basis, or as brokers ; ou comme courtiers; Confectionner toutes sortes d'accoutrements, To manufacture all kinds of ladies and children pour femmes et enfants, particulièrement des wears, skirts and waist particularly ; jupes et des gilets ; Faire aucune convention pour le partage des To enter into agreements for sharing of profits, bénéfices, l'union des intérêts, ou aucun autre union of interest, or any similar joint adventure risque mutuel semblable que la corporation with any persons, firms or companies, wliich the estimera avantageuse, avec aucunes autres company may think fit ; personnes, sociétés ou compagnies ; Souscrire, prendre ou autrement acquérir des To subscribe for, take or otherwise acquire parts et valeurs d'aucune autre corporation dont shares and securities of any company having les objets sont totalement ou partiellement objects altogether or partly similar to those of semblables à ceux de la présente compagnie, les the present company, to hold, sell or otherwise détenir, les vendre ou autrement les négocier ; dispose oi same ; Acquérir et assumer la totalité ou aucune To acquire and make over the whole or any partie de commerce de la propriété et du passif part of the business property and liabilities of any d'aucune personne ou corporation exerçant aucun persons or corporation carrying on any business négoce auquel se livre la présente compagnie, et which the present corporation carries on, and pay les payer en tout ou en partie avec des actions for the same wholly or partly, with paid up libérées de la présente corporation ; shares of the present company ; i Emettre et distribuer des parts acquittées et To issue and allot paid-up and non-assessable non sujettes à appel, des obligations, des actions- shares, bonds, debenture-stock, or other securities obligations et d'autres valeurs de la compagnie of the company, and with the approval of the et avec l'assentiment des actionnaires, s'en servir shareholders to pay with same for any services, pour payer les services, dettes ou autres obliga- debts, or liabilities of the company ; lions de la corporation ; Généralement avoir la jouissance de tous les Generally to liave the enjoyment of all powers pouvoirs afférents à l'exercice du susdit commerce, attached to the carrying on of the foresaid sous le nom de \"The Canadian Skirt & Waist business, under the name of \"The Canadian Manufacturing Company, Limited\", avec un Skirt & Waist Manufacturing Company, Limi- fonds social de dix-neuf mille cinq cents piastres ted\", with a capital stock of nineteen thousand ($19,500.00), divisé en mille neuf cent cinquante five hundred dollars ($19,500.00), divided into (1950) parts de dix piastres ($10.00) chacune.one thousand nine hundred and fifty (1950) shares of ten dollars ($10.00) each.La principale place d'affaires de la corporation, The principal place of the business of the corpo- sera à Montréal.tion, will be in Montreal.Daté au bureau du secrétaire de la province, ce Dated from the office of the Provincial Secre- vingt-troisième jour d'août 1917.tary, this twenty third day of August, 1917.Le sous-secrétaire de la province, C.-J.SIMARD, 3991\u201435-2 C.-J.SIMARD.3992\u201435-2 Assistant Provincial Secretary. 1943 Département de l'instruction publique Department of Public Instruction 1182-17.Québec.27 août 1917.I>e surintendant donne avis qu'il a reçu une requête demandant de détacher de la municipalité scolaire de Leeds, dans le comté de Mégantic, les lots Nos 14 des rangs 11 et 12, et le lot No 11 du rang 12 du cadastre officiel de la paroisse de Leeds, et de les annexer à la municipalité scolaire de Leeds-Est, même comté.3979\u201435-2 No 1318-Elec.Nominations de commissaires d'écoles.Il a plu à Son Honneur le lieutenant-gouverneur, par un arrêté en conseil, en date du 23 août 1917, de nommer MM.Joseph Meagher et Moses Donohue, commissaires d écoles pour la municipalité de Percé, dans le comté de Gaspé.3981 No 1502-Elec.Il a plu à Son Honneur le lieutenant-gouverneur, par un arrêté en conseil, en date du 23 août 1917, de nommer M.Edgar Dubé, commissaire d'écoles pour la municipalité de Saint-Samuel-de-Gavhurst, dans le comté de Frontenac.3983 No 475-Elec.Il a plu à Son Honneur le lieutenant-gouverneur, par un arrêté en conseil, en date du 23 août 1917, de nommer MM.Arthur Allaire et Adjutor Lemieux, commissaires d'écoles pour la municipalité de Saint-David-de-l'Auberivière dans le comté de I^évis.3985 No 681-Elec.Il a plu à Son Honneur le lieutenant-gouverneur, par un arrêté en conseil, en date du 23 août 1917, de nommer M.Edouard Letendre, commissaire d'écoles pour la municipalité de la ville de Saint-Germain, dans le comté de Rimouski.3987 No 1024-Elec.Il a plu à Son Honneur le lieutenant-gouverneur, par un arrêté en conseil, en date du 23 août 1917, de nommer MM.Joseph Gadoury et Joseph Valiquette, commissaires d'écoles pour la municipalité de canton Loranger, dans le comté de Labelle.3989 Québec, 16 août 1917.Le surintendant donne avis qu'il a reçu une requête demandant de détacher de la municipalité scolaire de Templeton-Est dans le comté d'Ottawa, les lots numéros 2,3 et 4 du rang 6 du canton Templeton, et de les annexer à la municipalité scolaire de L'Ange-Gardien, comté de Labelle.3875\u201434-2 Québec, 18 août 1917.Le surintendant donne avis qu'il a reçu une requête demandant de détacher de la municipalité scolaire de Privât, dans le comté de Témis-camingue, les lots Nos 1 à 31, inclusivement, du rang 1 du canton Languedoc et des rangs 9 et 10 du canton Privât, et de former de tout ce territoire une municipalité scolaire distincte sous le nom de Languedoc.3877\u201434-2 1182-17.Quebec, 27th August, 1917 Notice is given by the superintendent that application is made to detach from the school municipality of Leeds, hi the county of Megantic, the lots Nos.14 of ranges 11 and 12, and the lot No.11 of range 12 of the official cadastre of the parish of Leeds, and to annex said lots to the school municipality of Leeds East, same county.3980\u201435-2 No.1318-Elec.Appointments of school commissioners.His Honour the Lieutenant Governor 1ms lx»en pleased, by Order-in-Council, dated the 23rd August, 1917, to appoint Messrs.Joseph Meagher and Moses Donohue, school commissioners for the municipality of Percé, in the county of Gaspé.3982 No.1502-Elec.His Honour the Lieutenant Governor has been pleased, by Order-in-Council, dated the 23rd August, 1917, to Appoint Mr.Edgar Dubé, school commissioner for the municipality of Saint Samuel-de-Gavhurst, in the county of Frontenac.3984 No.475-Elec.His Honour the Lieutenant Governor has been pleased, by Order-in-Council, dated the 23rd August, 1917, to appoint Messrs.Arthur Allaire and adjutor Lemieux, school commissioners for the municipality of Saint David-de-1'Auberiviêre, in the county of Levis.3986 No.681-Elec.His Honour the Lieutenant Governor has been pleased, by Order-in-Council, dated the 23rd August, 1917, to appoint Mr.Edouard Letendre, school commissioner for the municipality of the town of Saint Germain, in the comity of Rimouski.3988 No.1024-Elec.His Honour the Lieutenant Governor has been pleased, by Order-in-Council, dated the 23rd August, 1917, to appoint Messrs.Joseph Gadoury and Joseph Valiquette, school commissioners for the municipalitv of township Loranger, in the county offLabelle.3990 Quebec, 16th August, 1917.Notice is given by the superintendent that application is made to detach from the school municipality of Templeton-East.in the county of Ottawa, the lots numbers 2, 3 and 4 of range 6 of Templeton township, and to annex same to the school municipality of L'Ange-Gardien, county of Labelle.3876\u201434-2 Quebec, 18th August, 1917.Notice is given by the superintendent that application is made to detach from the school municipality of Privât, in the county of Temisca-iiling, the lots Nos.1 to 31, both inclusive, of range 1 of Languedoc township and of ranges 9 and 10 of Privât township, and to erect all the above territory into a distinct school municipality under the name of Languedoc.3878\u201434-2 1944 322-17.Québec.20 août 1917.La surintendant donne avis qu'il a reçu une requête; demandant d'ériger en municipalité scolaire distincte les lots Nos 1 à 28,inclusivement, des rangs 4 et 5 du canton 1 récession, dans le comté de Témiscamingue, sous le nom de Ville-montel.3879\u201434-2 322-17.Quebec, 20th August, 1917.Notice is given by the suj>erintendent that application is made to erect into a distinct school municipality the lots Nos 1 to 28, both inclusive, of ranges 4 and 5 of Trecession township, in the county of Temiscaming, under the name of Ville-montel.3880\u201434-2 Département du trésor (service des assurances) Avis est par le présent domié que le certificat d'enregistrement accordé à \"The Canadian Surety Company\", autorisant cette compagnie à transiger dans la province de Québec des affaires d'assurance de garantie, l'assurance contre le vol et l'assurance contre le bris des glaces a été, ce jour, modifié lui accordant le droit de transiger l'assurance de l'automobile.Le nom et l'adresse de l'agent en chef pour la province de Québec sont: W.-E.Findley, Montréal.Que.Donné conformément à l'article 0950 S.R.P.Q.1909, ce quinzième jour d'août 1917.Pour le trésorier de la province de Québec.L'assistant trésorier provincial.3859-34-2 ALEX.HYDE.Actes de vente et certificats déposés Treasury Department (Insurance Branch) Notice is hereby given that the certificate of registry issued to The Canadian Surety Company, authorizing it to transact throughout the Province of Quebec the business of guarantee, burglary and plate glass insurance has, this day, been extended to include the business of automobile insurance.The name and address of the chief agent for the Province of Quebec are: W.-E.Findley, Montreal, Que.Given pursuant to article 0950, R.S.P.Q., 1909.this fifteenth day of August, 1917.For the treasurer of the province of Quebec.ALEX.HYDE 3800\u201434-2 Assistant Provincial Treasuver.Deeds of sale and certificate deposited En vertu de l'acte des liquidations.Canada, province de Québec, district de Québec.No 152.Dans l'affaire de \"The Quebec Home Builaers, Ltd.\" en liquidation.Avis est par le piésent donné qu il a été déposé au bureau de A.Thériault, 52 rue Saint-Joseph, à Québec, liquidateur de ladite compagnie en liquidation, un certain acte de vente passé devant Mtre J.-E.Plamondon, notaire public, le 4ième jour d'août mil neuf cent dix-sept, sous le numéro 9190 des minutes du dit notaire de la.part de \"The Quebec Home Builders, Limited\", en liquidation, à L.-Théodule Beaudoin, dans lequel acte de vente la propriété transportée est décrite comme suit : Un terrain mesurant quarante pieds de front par quatre-vingt-dix de profondeur, plus ou moins\u2014avec maison dessus construite, située coin de l'avenue Pine, sur la ligne du Quebec Railway, connu et désigné sous le No 220 subdivision du lot originaire 105 du cadastre officiel de Saint-Colomban de Sillery; borné au nord par la ligne du Quebec Railway, au sud par une ruelle, à l'est par l'avenue Pine, et à l'ouest par le No 221 du lot originaire 105, tel que le tout se trouve présentement.Et de plus prenez avis que le certificat du régistrateur sur ladite propriété a été déposé chez le liquidateur à son bureau, à Québec.Que la propriété ci-haut décrite a été détenue et possédée par \"TheQuebec Home Builders, Ltd\", depuis le 12 novembre 1915 jusqu'au 27 janvier 1917 et par William Richmond Pugh depuis le 27 janvier 1917 jusqu'au 22 mai 1917, date à laquelle ladite propriété a été rétrocédée à \"The Quebec Home Builders, Limited\", en liquidation.Que lesdits actes de vente et certificats du régistrateur ont été ainsi déposée en conformité Under the winding-up act.Canada, province of Quebec, district of Quebec.No.152.In the matter of : The Quebec Home Builders, Ltd, in liquidation.Notice is hereby given that there has been lodged at the office of A.Thériault, 52 Saint Joseph street, at Quebec, a certain deed of sale passed bofore J.-E.Plamondon, esquire, notary public, on the 4th day of August, one thousand nine hundred and seventeen, under the number 9196 ot the minutes of said notary, on behalf of The Quebec Home Builders, Limited, in liquidation, to L.-Théodule Beaudoin, in which deed of sale the property conveyed is described as follows : That certain lot of land measuring forty feet in front by ninety feet in depth, more or less-with a house thereon erected, situated at the corner of Pine Avenue, on the Quebec Railway line, known and designated under the No.220 of the subdivision of primitive lot number 105, of the official cadastre of the parish of the Saint Colomb of Sillery ; bounded on the north by the Quebec Railway line, on the south by a lane, on the east by Pine Avenue, and on the west by lot No.221 of the subdivision of said primitive lot number 105, as the whole now subsists.And take further notice that the Registrar's certificate on said property has been deposited with the liquidator, at his office, at Quebec.That the above described property was owned and possessed by The Quebec Home Builders.Ltd, from the 12th November, 1915 to the 27th January, 1917, and by William Richmond Pugh from the 27th January, 1917 to the 22nd May, 1917, on which date it was re-conveyed to The Quebec Home Builders, Ltd, in liquidation.That the said deeds of sale and Registrar's certificates have been deposited in compliance 1945 avec les prescriptions des articles 7552-7553-7554-7555-7556-7557 des Statuts retondus de la province de Québec, 1909, et que le présent avis est publié en conformité des dispositions desoits articles et afin de donner a ladite vente l'effet d'une vente faite par le shérif.Daté à Québe., ce 4ième jour d'août 1917.Le liquiaateur, A.THERIAULT.Québec, 4 août 1917.3727\u201432-4 with the provisions of articles 7552-7553-7554-7555^7556-7557 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1909.and the present notice is published pursuant to the provisions of said articles so as to give said sale the effect of a sheriff's sale.Dated at Quebec, this fourth day ot August, 1917.A.THERIAULT, Liquidator.Quebec, 4th August, 1917.3728\u201432-4 Actions en séparation de biens Actions for separation as to property Province de Québec, district de Montréal, cour supérieure.No 4808.Dame Bella Gibsh, épouse commune en biens de Sam Gilman, marchand, tous deux de la cité et du district de Montréal, et dûment autorisée à ester en justice, demanderesse; vs Sam Gilman, marchand, du même lieu, défendeui.Une action en séparation de biens a été intentée en la présente cause, le 20 août 1917.Le procureur de la demanderesse.N.SOLOMON.Montréal, le 23 août 1917.3949\u201435-5 Province de Québec, district de Montréal, cour supérieure, No 1380.Dame Esther Taylor, de la cité et du district de Montréal, épouse commune en biens d'Abraham Rosenberg, du même lieu, et dûment autorisée aux fins des présentes, demanderesse; vs Abraham Rosenberg, du même lieu, défendeur.Une action en séparation de biens a été intentée en cette cause, le 21 août 1917.Le procureur de la demanderesse, I.POPLIGER.Montréal, 23 août 1917.3951\u201435-5 Province de Québec, district de Chicoutimi, cour supérieure, No 5498.Dame Elodie Gagnon, épouse commune en biens de Orner Harmegnies, jardinier, de Jonquière, et dûment autorisée à ester en justice; vs le dit Orner Harmegnies.Une action en séparation de biens a été instituée contre le défendeur, le 17 août 1917.Le procureur de la demanderesse, 3861\u201434-5 ONESIME TREMBLAY.Cour supérieure, Beauce, No 3451.Dame Florida Lagrange, épouse commune en biens d'Omer Turcotte, de la paroisse de Saint-Benjamin, district de Beauce, dûment autorisée à ester en justice, demanderesse; vs ledit Omer Turcotte, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause, le 21 août 1917.Les procureurs de la demanderesse, 3885\u201434-5 PACAUD & MORIN.Province de Québec, district de Montréal, cour supérieure, No 1234.Dame Anna McMichael, des cité et district de Montréal, épouse commune en biens de René Beauchemin, gérant, du même endroit, demanderesse ; vs ledit René Beauchemin, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause, ce 3 août 1917.L'avocat de la demanderesse, 3733\u201432-5 RENE CHENEVERT.Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court.No.4808.Dame Bella Gibsh, wife common as to property of Sam Gilman, merchant, both of the city and district of Montreal, and duly authorized to ester en justice, plaintiff ; vs Sam Gilman, merchant, of the same place, defendant.An action in separation as to property has been instituted in this cause, on the 20th clay of August, 1917.N.SOLOMON, Attorney for plaintiff.Montreal, 23rd August, 1917.3950\u201435-5 Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court.No.1380.Dame Esther Taylor, of the city and district of Montreal, wife common as to property of Abraham Rosenberg, of the same place and duly authorized for the purposes herein, plaintiff; vs Abraham.Rosenberg, of the same place, defendant.An action for separation as to property has been instituted in this cause, on the 21st of August, 1917.I.POPLIGER, Attornev for plaintiff.Montreal, 23rd August, 1917.\"3952\u201435-5 Province of Quebec, district of Chicoutimi, Superior Court, No.5498.Dame Elodie Gagnon, wife common as to property of Omer Harmegnies, gardener, of Jonquière, and duly authorized to ester en justice; vs the said Omer Harmegnies.An action in separation as to property has been entered against the defendant, on the 17th of August, 1917.ONESIME TREMBLAY, 3802\u201434-5 Attorney for plaintiff.Superior Court, Beauce, No.3451.Dam Florida Lagrange, wife common as to property o Omer Turcotte, of the parish of Saint Benjamin district of Beauce, duly authorized to ester en justice, plaintiff; vs the said Omer Turcotte, defendant.An action for separation as to property has been instituted in this cause, on the 21st of August, 1917.PACAUD & MORIN, 3886\u201434-5 Attorneys for plaintiff.Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.1234.Dame Anna McMichael, of the city and district of Montreal, wife common as to property of René Beauchemin, of the same place, manager, plaintiff ; vs the said René Beauchemin, defendant.An action in separation as to property has been instituted in this cause, on the 3rd August, 1917.RENE CHENEVERT, 3734\u201432-5 Attorney for Plaintiff. 1946 Province de Québec, district de Terrebonne, dans la cour supérieure, No 92b'.Dame Rachel Biais, de la ville de Lachute, district de Terre-bonne, épouse de Aldéric l.uviimr, commerçant du même lieu, dûment autorisée à ester en justice, demanderesse; vs ledit Aldéric La vigne, défendeur Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause, le dix-huitième jour du mois d'août 1917.Ijc procureur de la demanderesse, L.-L.LEGAULT.Sainte-Scholastique, 18 août 1917.3887\u201434-5 Canada, province de Québec, district de Québec, cour supérieure.No 2652.Dame Alma Bergeron, de Québec, épouse commune en biens de Odilon Vézina, plombier, de Québec, dûment autorisée à ester en justice, demanderesse; vs ledit Odilon Vézina.défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause, le dix-septième jour d'août 1917.LANE & LEMIEUX, Procureurs de la demanderesse, Québec, 20 août 1917.3889\u201434-5 Province of Quebec, district of Terrebonne, Superior Court, No.926.Dame Rachel Biais, of the town of I .achate, district of Terrebonne, wife ol Aldéric I .avigne, trader, of the same place, duly authorized to ester en justice, plaintiff; vs the said Aldéric Lavigne, défendant.An action for separation as to property has been instituted in this cause, on the eighteenth day of the month of August, 1917.L.-L.LEGAULT, Attorney for plaintiff.Sainte Scholastique, 18th August, 1917.3888\u201434-5 Province de Québec, district des Trois-Rivières, cour supérieure, No 48.Dame Ophédie Thi-beault, épouse de Emmanuel Simard, maître-cliarron, de Lac-à-Beauce, dans le district des Trois-Rivières, dûment autorisée à ester en justice, demanderesse ; vs ledit Emmanuel Simard, de Lac-à-Beauce, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause, le 17 juillet 1917.Le procureur de la demanderesse, C.-ROMULUS DUCHARME, Trois-Rivières, 18 juillet 1917.3685\u201432-5 Province de Québec, district de Montréal, cour supérieure, No 3974.Dame Casilda Contant, de la ville de Montréal-Nord, district de Montréal, épouse commune en biens de J.-Wilfrid Pion, du même lieu, marchand, et dûment autorisée à ester en justice par cette honorable cour, demanderesse ; vs ledit J.-Wilfrid Pion, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 31 juillet 1917.Les procureurs de la demanderesse, LAMARRE & MONET.92 Notre-Dame-Est, Montréal.Montréal, 31 juillet 1917.3687\u201432-4 Province de Québec, district de Montréal, cour supérieure, No 579.Dame Valéda Sauvé, épouse de Zenon Charlebois, commerçant, de Saint-Joseph-de-Soulanges, dûment autorisée à ester en justice, avec lequel elle est domiciliée et résidente, a formé une demande en séparation de biens contre son mari, Montréal, 31 juillet 1917.L'avocat de la demanderesse, 3609\u201431-5 J.-OCTAVE MOUSSEAU.Dame Sophie Isseson, de la cité et du district de Montréal, épouse commune en biens de Max Rudnikoff et duement autorisée à ester en justice, demanderesse ; vs Max Rudnikoff, du même lieu, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée contre le défendeur, le 27 juillet 1917.Le procureur de la demanderesse, 3611\u201431-5 I.POPLIGER.Canada, province of Quebec, district ot Quebec, Superior Court, No.2652.Dame Alma Bergeron, of Quebec, wife common as to property of Odilon Vézina, plumber, of Quebec, duly authorized to ester m justice, plaintiff; vs the said Odilon Vézina, defendant.An action for separation as to property has been instituted in tins cause, on the seventeenth of August, 1917.LANE & LEMIEUX, Attorneys for plaintiff.Quebec, 20th August, 1917.3890\u201434-5 Province of Quebec, district of Three-Rivers, Superior Court, No.48.Dame Ophedie Thi-beault, wife of Emmanuel Simard, wheelwright, of Lac-à-Beauce, in the district of Three Rivers, duly authorized to ester en justice, plaintiff ; vs the said Emmanuel Simard, of Lac-à-Beauce, defendant.An action for separation as to property has been instituted in this cause, on the 17th of July, 1917.C.-ROMULUS DUCHARME, Attorney for plaintiff.Three Rivers, 18th July, 1917.3686\u201432-5 Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.3974.Dame Casilda Contant, of the city of Montreal-Nord, district of Montreal, wife common as to property of J.Wilfrid Pion, of the same place, merchant, and duly authorized by this Honourable Court, for the purposes herein, plaintiff ; vs the said J.Wilfrid Pion, defendant.An action in separation as to property has been instituted in this cause on 31st July, 1917.LAMARRE & MONET, Attorneys for Plaintiff.90 Notre-Dame-East, Montreal.Montreal, 31st July, 1917.3688\u201432-4 Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.579.Dame Valeda Sauvé, wife of Zenon Charlebois, trader, of the parish of Saint Joseph-of-Soulanges, duly authorized, with whom she is domicilized and residing, has instituted an action in separation as to property from her husband, Montreal, July 31st, 1917, J.-OCTAVE MCUSSEAU, 3610\u201431-5 Solicitor for plaintiff.Dame Sophie Isseson, of the city and district of Montreal, wife common as to property of Max Rudnikoff and duly authorized to ester en justice, plaintiff ; vs Max Rudnikoff, of the same place, defendant.An action in separation as to property has been entered against the defendant, on 27th July, 1917.I.POPLIGER, 3612\u201431-5 Attorney for plaintiff. 1947 Province de Québec, district de Montréal, Cour supérieure, No 3238.Dame Rose-Anna Beauregard, des cité et district de Montréal, épouse commune en biens de Joseph Lussier, du môme lieu, conducteur de tramways, et dûment autorisée a ester en justice aux fins des présentes, en vertu d'un jugement de cette honorable cour, demanderesse ; vs ledit Joseph Lussier, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause, ce jour.Les avocats de la demanderesse, BROSSARD & PEPIN.Montréal, le 27 juillet 1917.3633\u201431-5 Assemblée Province of Quebec, district of Montreal.Superior Court, No.3238.Dame Rose-Anna Beauregard, of the city and district of Montreal, wife common as to property of Joseph Lussier, of the same places conductor of tramways, and duly authorized by this Honourable Court for the purposes herein, plaintiff ; vs the said Joseph Lussier, defendant.An action in separation as to property has been instituted in this cause, on the 27th day of July, 1917.BROSSARD & PEPIN, Attorneys for plaintiff.Montreal, 27th July, 1917.3034\u201431-5 Meeting La Compagnie du chemin de fer de la baie des Ha ! Ha ! AVIS D'ASSEMBLEE D'ACTIONNAIRES.Avis est par le présent donné que l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie du chemin de fer de la baie des Ha! Ha! aura lieu à la chambre No 705, édifice de la \"Dominion Express\", 145 rue Saint-Jacques, cité de Montréal, province de Québec, mercredi, le ciuq-ième jour de septembre 1917, à midi, pour entendre le rapport des directeurs sur la dernière année, élire les officiers, nommer les auditeurs, ratifier les règlements et un contrat intervenu, le 20 novembre 1910, entre la compagnie du chemin de fer de la baie des Ha ! Ha !, J.-E.-A.Dubuc et la Union Trust Company, Limited, lequel contrat prévoit, entr'autres choses, la substitution d'une nouvelle emprise à une partie de la présente, on y transigera aussi toute autre affaire qui pourra être soumise à la considération de l'assemblée.Daté le 10 août, a.d.1917.Le secrétaire, 3803\u201434-2 H.BURCH.The Ha ! Ha ! Bay Railway Company NOTICE OF SHAREHOLDERS' MEETING.Notice is hereby given that the general annual meeting of the shareholders of the Ha! Ha! Bay Railway Company will be held at room No.705 Dominion Express Building, 145 Saint James street,in the city of Montreal, Province of Quebec, on Wednesday the fifth day of September, 1917, at the hour of twelve o'clock noon, to receive the directors' report for the past year, for the election of directors, appointment of auditors, confirmation of by-laws, confirmation of an agreement, dated November 20th,1910 between The Ha! Ha! Bay Railway Company, J.-E.-A.Dubuc and The Union Trust Company Limited, including amongt other things therein contained, the substitution of new right of way for a portion of the present right of way, and the transaction of any other business which may be brought before the meeting.Dated the 10th day of August, A.D., 1917.H.BURCH, 3804\u201434-2 Secretary.Faillite Province de Québec, district de Richelieu, cour supérieure, No 6144.Dans l'affaire de DuGueslin Magnan, commerçant, de la cité de Sorel, district de Richelieu, failli.Avis est donné que le sixième jour du mois d'août 1917, le soussigné a été nommé, par une ordonnance de la cour, gardien aux biens dudit Dugueslin Magnan, qui a fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers.Le gardien provisoire, C.-J.-A.TURCOTTE.Sorel, 22 août 1917.3953 Re: J.-M.Vézina, de Saint-Narcisse, Que., marchand, insolvable.Avis estpar le présent donné qu'un premier et dernier dividende a été préparé dans cette affaire et sera sujet à objection d'ici au 17 septembre 1917, et sera payable à nos bureaux, le ou après le 18 septembre 1917.Les curateurs conjoints, LEFAIVRE & GAGNON Bureaux: 147 Côte de la Montagne, (Edifice Bossé), Québec, 28 août 1917.3965 Bankruptcy Province of Quebec, district of Richelieu, Superior Court.No.6144.In the matter of DuGueslin Magnan, trader, of the city of Sorel, district of Richelieu, insolvent.Notice is hereby given that on the sixth day of the month of August, 1917, the undersigned was appointed, by an order of the court, guardian to the property of said DuGueslin Magnan, who made an assignment of his property for the benefit of his creditors.C.-J.-A.TURCOTTE, Provisional guardian.Sorel, 22nd August, 1917.3954 Re: J.-M.Vézina, of Saint Narcisse, Que., merchant, insolvent.Notice is hereby given that a first and final dividend has been prepared in the above matter and will be Subject to objection until 17th September, 1917, and will be payable at our offices, on or after 18th September, 1917.LEFAIVRE & GAGNON, Joint curators.Offices: 147 Mountain Hill, (Bossé Building), Quebec, 28th August, 1917.3966 . 1948 Province de Québec, district de Montréal, cour suj)érieure, No 189.Dans l'affaire de Jean Brunetli, No 17 avenue du Collège McGill, failli.Avis vous est par la présente doimé qu'en vertu d'un jugement rendu en cour suj)érieure, ce 27e jour d'août mil neuf cent dix-sept, le soussigné a été nommé curateur aux biens dudit failli.Ijes créanciers sont priés de produire leurs réclamations assermentées à mon bureau sous trente jours du présent avis.Le curateur, OSCAR BEAUCHAMP Chambre 13-15 édifice \"Lfl Presse\", 51 rue Saint-Jacques, Montréal, 27 août 1917.3967 Province de Québec, district de Montréal, cour suj)érieure, No 195.Dans l'affaire de \"Wel-land Hotel Co., Ltd\", en liquidation.Avis est par la présente donné qu'en vertu d'un jugement rendu en cour supérieure, ce 28e jour du mois d'août 1917, le soussigné a été nommé liquidateur de la compagnie en liquidation.Les créanciers sont priés de produire leurs réclamations assermentées à mon bureau sous trente jours du présent avis.Le liquidateur, OSCAR BEAUCHAMP.Chambre 13-15 édifice \"La Presse\", 51 rue Saint-Jacques, Montréal, 28 août 1917.3969 Province de Québec, district de Montréal, cour supérieure, No 194.Dans l'affaire de François-Xavier Quévillon, manufacturier, 909 rue Henri-Julien, Montréal, failli.Avis est par le présent donné que le 27ème jour d'août 1917, par un ordre de cette cour, les soussignés ont été nommés curateurs aux biens dudit failli.Les réclamations, attestées sous serment, doivent être produites entre nos mains dans les trente jours de cet avis.Les curateurs, J.-A.BENOIT, L.-T.-B.de GROSBOIS.Bureau: 20 rue Saint-Jacques, Montréal, 27 août 1917.3973 Province de Québec, district de Montréal, cour supérieure.Stanley-Colville Levy, de la cité et du district de Montréal, négociant, faisant affaires seul sous les nom et raison sociale de \"Colville's\".Avis est par le présent donné que le 24 août 1917, par ordonnance de la cour, le soussigné a été nommé curateur aux biens dudit Stanley-Colville Levy, qui en a fait cession judiciaire au bénéfice de ses créanciers.Les réclamations, assermentées, doivent être produites chez moi sous trente jours de la présente date.Le curateur, HENRY-J.FITZGERALD.Bureau de FitzGerald & Ellis, 591 rue Sainte-Catherine-Ouest.Montréal, 25 août 1917.3977 Province de Québec, district de Montréal, cour supérieure, No 201.Dans l'affaire de Tan-crède Benoit, fils, épicier-boucher, 181 rue Desery, Montréal, failli.Avis est par le présent donné que le susdit failli a fait une cession judiciaire de ses biens, le 25 Province pf Québec, district of Montreal, Superior Court, No.189.In the matter of Jean Brunetti, No.17 McGill College Ave., failed.Notice is hereby given by this present that in virtue of a judgment rendered in Sujxîrior Court, the 27th day of August, nineteen hundred and seventeen, the undersigned has been appointed curator for the said estate.Creditors of the said insolvent are requested to fyle their claims, duly sworn, at my office in thirty days of the present notice.OSCAR BKAUCIIAMP, Curator.Rooms 13-15 La Presse bldg., ' 51 Saint James street, Montreal.27th August, 1917.3908 Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court.No.195.In the matter of \"The Welland Hotel Co., Ltd\", in liquidation.Notice is hereby given that in virtue of a judgment rendered in Suj>erior Court, the 28th day of August, 1917, the undersigned has been a|>-pointed liquidator for the said company in liquidation.Creditors of the said insolvent are requested to fyle their claims, duly sworn, at my office in thirty days of the present notice.OSCAR BEAUCHAMP, Liquidator.Room 13-15 \"La Presse\" bldg., 51 Saint James street, Montreal, 28th August, 1917.3970 Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.194.In the matter of François-Xavier Quevillon, manufacturer, 909 Henri-Julien street, Montreal, insolvent.Notice is hereby given that on the 27th day of August, 1917, by an order of the Court, the undersigned were appointed curators to the property of the aforesaid insolvent.Sworn claims must be filed with us within thirty days from this notice.J.-A.BENOIT, L.-T.-B.de GROSBOIS, Curators.Office: 20 Saint James street, Montreal, 27th August, 1917.3974 Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court.Stanley-Colville Levy, of the city and district of Montreal, merchant trader, doing business alone under the firm, name and style of \"Colville's\".Notice is hereby given that on the 24th day of August, 1917, by an order ot the Court, the undersigned was appointed curator to the property of the said Stanley-Colville Levy, who has made a judicial abandonment of his property for the benefit of his creditors.Sworn claims must be fyled with me within 30 days from this date.HENRY-J.FITZGERALD, Curator.Office of FitzGerald & Ellis, 591 Saint Catherine street West.Montreal, 25th August, 1917.3978 Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.201.In the matter of Tan-crède Benoit, junior, grocer and butcher, 181 Desery street, Montreal, insolvent.Notice is hereby given that the aforesaid insolvent has, on the 25th August, 1917, made a judicial 1949 août 1917.au bénéfice de ses créanciers, au bureau du protonotaire de la cour su|)érieure, à Montréal.I>i gardien provisoire, S.DECOSSE.Montréal, 27 août 1917.3975 assignment of his property for the benefit of lus creditors, at the oflice of the prothonotary of the Superior Court, at Montreal.S.DECOSSE, Provisional guardian.Montreal, 27th August, 1917.3976 Vente par licitation Canada, province de Québec, district de Montréal, cour suj>érieure, No 1810, Demoiselle Aurore Bénard, demanderesse; vs Ferdinand Bénard, es-qual., et a\\., défendeurs.Avis est donné en vertu d'un jugement de la cour supérieure, siégeant à Montréal, dans le district de Montréal, rendu le 31 juillet 1917, dans cette cause, dans laquelle ladite demoiselle Aurore Bénard est demanderesse ; et lesdits Ferdinand Bénard, bourgeois, de Montréal, en sa qualité de curateur à la personne et aux biens de Théodule Bénard, ingénieur, de la ville de Longueuil, district de Montréal et maintenant interdit pour démence; Gustave Bénard.pompier, de Montréal, Louis-A.Jodoin, bourgeois, du même lieu, en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne des trois filles mineures, Adrieime, Juliette et Aline, issues du mariage dudit Théodule Bénard avec Dame Amanda Auger, maintenant décédée, sont défendeurs, ordonnant la licitation d'un certain immeuble désigné comme suit, savoir : \"Un emplacement ayant front sur le chemin Chambly, en la ville de Longueuil, de fdrme irrégulière, contenant une superficie de 10,150 pieds, mesure française, avec une maison et autres dépendances dessus construites, portant le numéro civique 58 du chemin Chambly; ledit emplacement connu et désigné comme le lot No 323, aux plan et livre de renvoi officiels du village de IiOiigueuil, dans le comté de Chambly, en arrière par la rue Caroline, d'un côté par le lot No 321 et 322, sur ledit plan, et de l'autre côté, partie par le lot No 324 et partie par une partie dudit lot No 325, sur le môme plan.L'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur, le CINQ-IEME jour d'OCTOBRE 1917, cour tenante, en la salle d'audience du palais de justice de Montréal, chambre No 3L, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au greffe du protonotaire de ladite cour; et que toute opposition à fin d'annuler, à fin de charge ou à fin de distraire à ladite licitation, devra être déposée au greffe du protonotaire de ladite cour, au moins douze jours avant le jour fixé, comme susdit pour la vente et adjudication; et que toute opposition à fin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication et, à défaut par les parties de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par le présent, elles seront forcloses du droit de le faire.L'acquéreur dudit immeuble devra déposer, au moment de l'adjudication, la somme de $600.00 en acompte sur son prix d'achat et la balance dans les trois jours qui suivront la vente.Les avocats et procureurs de la demanderesse, PELLETIER, LETOURNEAU, BEAULIEU & MERCIER.Montréal, 24 août 1917.3971\u201435-2 Sale by Licitation Canada, province of Quebec, district of Montreal, in the Superior Court.No.1810, Miss Aurore Benard.plaintiff, vs Ferdinand Benard es-qual., et al., defendants.Public notice is hereby given that under and by virtue of a judgment of thfc Sifjrcrior Court, sitting at the city of Montreal, in the district of Montreal, in the thirty first day of July, one thousand nine hundred and seventeen, hi this cause, in which the said Miss Aurore Benard is plaintiff; and the said Ferdinand Benard, gentleman, of Montreal, in his qualify of curator to the body and property of Theodule Benard, engineer, of the town of Ixmgueuil, district of Montreal, and now interned for insanity Gustave lienard; fireman, of Montreal.Louis-A.Jodoin, gentleman, of the same place, in his capacity of tutor to the body and property of the three minor daughters, Adrienne, Juliette and Aline, issued of the marriage of the said Théodule Benard and Darne Amanda Auger, now deceased, are defendants, ordering the licitation of certain immoveable property described as follows, to wit : \"An emplacement fronting on Chambly road, in the town of Longueuil, of irregular form, containing an area of 10,150 feet, French measure, with a house and other buildings thereon erected, bearing civic number 58 of Chambly road; the said emplacement known and designated as, the lot No.323, on the official plan and book of reference for the village of Longueuil, in the county of Chambly, in rear by Caroline street, on one side by lot No.321 and 322.on the said plan, and on the other side, part by lot No.324 and part by part of said lot No.325, on the same plan.The property above described will be put up to auction and adjuged to the last and highest bidder, on the FIFTH day of OCTOBER, 1917,sitting the court, in the court room of the court house, in the city of Montreal, room No.31, subject to the charges, clauses and conditions contained in the list of charges deposited in the prothonotary's office of the said court; and any opposition to annul, to secure charges or to withdraw, to be made to the said licitation must be fyled in said prothonotary's office of said court, twelve days at least before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication; and oppositions for payment must be fyled within six days next after the adjudication, and failing any parties to fyle such oppositions within the delays hereby limited, they will be forclosed from so doing.The purchaser of the said property shall deposit, at the time of adjudication, the sum of $600.00 as an account of the price of sale and the balance to be paid in the three days following this sale.PELLETIER, LETOURNEAU, BEAULIEU & MERCIER, Attorneys, for the plaintiff.Montreal, 24th August, 1917.3972\u201435-2 \\ Vente pour taxes Sale for taxes AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES.Avis public est par les présentes donné que les propriétés immobilières ci-après mentionnées, et plus spécialement désignées dans une cédule déposée dans mon bureaHi, le treizième jour d'aoCt 1917, seront vendues par moi, à mon bureau, dans la cité de Montréal, LUNDI, LE QUINZIEME jour d'OCTOBRE prochain 1917, à DIX heures de l'avant-midi, à raison d'une réclamation de la cité de Montréal, pour taxes et contributions foncières dues, telles que détaillées dans ladite cédule.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES.Public notice is hereby (riven that the immoveable properties mentioned and more particularly described in schedule filed in my office, the thirteenth day of August.1917, will lie sold bv me, at mv office, in the city of Montreal, on MONDAY, the FIFTEENTH day of OCTOBER next, 1917, at TEN o'clock in the forenoon, upon claim by the city of Montreal, for taxes and assessments due, aa detailed in the said schedule.Node la cédule Schedule No.Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed i Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes 7 8 21 28 29 30 33 34 41 44 46 Est\u2014East.Est\u2014East.Centre.Ouest\u2014West.S te-Anne.St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 8t.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 Ste.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.47 ISte-Anne\u2014 lSt.Ann'sf 52 173 31 66 226 et partie de\u2014 and part of 225 229 et-and 228 284 404 404 419, 418, 417 et-and 416 Partie de\u2014part of 673 Partie de\u2014part of 844 895 985 et partie de\u2014 and part of 984 311 355a, 355c et-and 357 91,93, 95 et-and 97 9 et-and 11 431, 435a.437 et-and 439 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 St-Paul.St-Louis.Des Commissaires.St-Sulpice.St-Paul.Parties de-part of 5 et-and 4 131.133.135.137, 137a 59, 61, 63 et\u2014and 65 68 et - and 60 17 et\u2014and 19 5896 et-and 589c 82, 82a, 84 et\u2014and 84a 80, 82, 84 et\u2014and 86 Succession - Estate Revd Marie Hercule Bédard.Napoléon Mathieu.Georges-H.LaI>1 i : 11 assessments.116.50 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.26.96 Cot isations spéciales\u2014 Special ?ssessmcnts.214 .31 Cotisât.,.ins annuelles\u2014 I Annual assessments.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Georges.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 Ste.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's. 48 ISte-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne.Ste-Anne\u2014 Ste.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.1016 1017 1018 1048, 1049 et-and 1050 Partie de\u2014part of 1165 1174 1232 Parties de - parts of 1284 et-and 1286 1370 et-and 1371 1435 Partie de\u2014part of 1468 1625 34 et\u2014and 36 32 26, 26a, 28, 30 Manufactures ¦ facturera.Manufactures facturera.Manufactures.206 St-Patrick.Notre-Dame.246a, 248, 250, 252a 742 et\u2014and 744 17 174 et-and 176 193c, 195, 195a, 197, 197a et\u2014and 1976 70a, 72 et\u2014and 74 62, 62a, 64 et-and 68 Richmond.123 Notre-Dame.Versailles.Murray.McCord.Murray.Colborne.Nazareth.Manufac- Isabella Oliver Elizabeth Oliver veuve de\u2014widow of William Pepper.- Manu- Isabella Oliver, Elizabeth Oliver, veuve de\u2014widow of William Pepper.Isabella Oliver, Elizabeth Oliver veuve de\u2014widow of William Pepper.Martin & Frère, Compagnie Limitée\u2014Limited.Rouer Roy \"Roy et Compagnie\".Sarah Klein, veuve de-widow of Isaac Workman.Joseph-M.Boudreau.Abraham William Jacobs Company, Limitée\u2014Limited.Samuel William Smith.Emma Louise Barbeau, Marceline Brosseau épouse de\u2014 wife of Thomas Lyon.Mary Cullinan, épouse de\u2014 wife of Charles McGinley, Johanna Cullinan, épouse de\u2014wife of Jeremiah Shea, Revd Andrew P.Cullinan, William John Cullinan, John J.Cullinan, Patrick Joseph Cullinan et\u2014and Margaret Cullinan.Mary Cullinan, épouse dt wife of Charles McGinley, Johanna Cullinan épouse de wife of Jeremiah Shea, Revd Andrew P.Cullinan, William John Cullinan, John J.Cullinan, Patrick Joseph Cullinan et\u2014and Margaret Cullinan.24.75 49.91 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.108.23 Cotisations annuelles et spéciales Annual and special assessments.37.45 88.05 552.04 542.76 786.63 544.33 119.20 160.88 92.97 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisationsannuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne-St.Ann's.Ste-Anne.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Node\t\t\t\t\t\t\t\t\tNoms des quar- la\tQuartier\tNo du cadastre\t\tNo de la rue\tRue\tPropriétaire cotisé\tMontant\tNature des réclamations ¦\ttiers pour fins cédule\t\t\t\t\t\t\t\t\tmunicipales __\t_\t_\tSubdivision\t_\t_ .\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014 Sche-\t\t\t\t\t\t\tAmount\t\tNames of wards dule\tWard\tCadastral No.\t\tStreet number\tStreet\tAssessed proprietor\tclaimed\tNature of claims\tfor municipal No.\t\t\t\t\t\t\t\t\tpurposes Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.1626 1775 Parties de \u2014 parts of 1788 et-and 1789 1796 1856 Partie de\u2014part of 335 385 465 465 466 466 466 10-1 9-1 15 19 20.21 121 44, 46 et\u2014and 48 384, 386.388, 390, 392, 394, 396 et-and 398 135, 137 et\u2014and 139 78, 80 et\u2014and 100 32, 36, 38 et\u2014and 40 170 259, 261 264.264a 280, 280a, 280b, 282, 282a, 2826 Nazareth.Inspecteurs\u2014Inspector.Notre-Dame Ouest-West.St-Maurice.I Mary Cullinan épouse de\u2014 wife of Charles McGinley, Johanna Cullinan épouse de wife of Jeremiah Shea, Revd Andre* P.Cullinan, William John Cullinan, John J.Cullinan, Patrick Joseph Cullinan et\u2014and Margaret Cullinan.Robert Duncan, Samuel Duncan et\u2014and David Duncan.Joseph Emile Desy, J.-Al-phonse Gagnon et\u2014and Joseph Edouard Palmer.Joseph Emile Desy, J.-Al-phonse Gagnon et\u2014and Joseph Edouard Palmer.92.96 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-Henri- St-Maurice.Cléophas St-Aubin.St-Martin.Ursule Paquette, veuve de-^- widow of Olivier Sauvé dit Laplante, Joseph Ernest Laplante.EdmondLaplante.St-Martin.St-Antoine.771, 771 M.771H.773 John-M.Ferguson.J.-Hormisdas Foisy.Aqueduc\u2014Aqueduct.Eugène Douesnard St-Jacques-St.James.François Villeneuve.St-Jacques\u2014St.James.I François Villeneuve.237.22 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.1,803.68 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.343.77 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.505.65 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.149.85 Cotisations annuelle*\u2014 Annual assessments.111.48 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.29.05 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.380.71 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessment.114.46 Cotisations annuelles et spéciales.\u2014 Annual and special assessments.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne\u2014 St.Ann's.Ste-Anne-St.Ann's.St-Joseph St-Joseph, * St-Joseph.St-Joseph.St-Joseph.St-Joseph.292.10 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments. 137 138 146 148 151 152 154 156 161 163 170 174 175 176 177 185 191 St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine., St-Antoine., St-Antoine.466 466 Partie de\u2014part of 486 593 Partie de\u2014part of 597 598, 599 Partie de\u2014part of 607 Partie de\u2014part of 607 677 695 791 Partie de\u2014part of 817 818 821 Partie de\u2014part of 834 896 967a, 968, 968a Parties de-parts of 963 et-and 972 33 34 193, 195 197, 199 727, 729 et-and 731 44.46 93 191, 193 93,95.97, 99, 101 580 578 669, 669a et-and 671 Versailles.Versailles.Notre-Dame-Ouest-Wes t Bonaventurc.Félix-Joseph Cusson.Félix-Joseph Cusson.Félix-Joseph Cusson.Alfred Hurtubise.Osborne.La Montagne-Mountain.103, 105.1056, 105c, 105d, 107 et\u2014and 109 25, 27, 29, 31 476, 478 108, 110 et-and 112 90, 90a.906, 92 et-and 92a 81, 83, 85 Osborne.Dorchester Ouest-West.! Dorchester Ouest-West.St-Jacques-St.James.St-Félix-Nord\u2014North.Cathédrale.St-Jacques-St.James.Inspecteur-Inspector.Inspecteur-Inspector.Inspecteur-Inspector.353, 355, 357, 359 Notre-Dame-Ouest-West 485, 487M St-Jacques-St.James.I.cil.ix Carriage Company, Limitée\u2014Limited.Lcdoux Carriage Company, Limitée\u2014Limited.The Crescent Turkish Bath Company, Limited-Limitée.George-C.Jackson, William M.Ma.han, Henry W.Schofield.City Estates,Limitée-Limited.Hermine Alain, épouse de wife of Charles Edmond Ranger.Oscar F.Berthiaume.Robert Duncan, David Duncan, Samuel Duncan.Robert Dunean, David Duncan, Samuel Dunean.Cléophas St-Aubin.Robert Dunean.David Dunean, Samuel Duncan.Delphine Chaput.veuve de\u2014 widow of Joseph Alfred La-ramée.Laird Paton and Sons, Limité Limited.100 M', r nti.-ations annuelles\u2014 Annual assessments.213.20 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.338 36 Cotisations annuelles\u2014 Annual Assessments.8.47 Cotisations spéciales.\u2014 Special assessments.594.22 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.3,082 10 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.'5.'571 so ( 'otisations annuelles\u2014 Annual assessments.1,115.96 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.513 96 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.213.84 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.675.50 Cotisations annuelles -Annual assessments.9S2.06 Cotisations annuelles-Annual assessments.830 62 ( 'otisations annuelles-Annual assessments.627.75 Cotisations annuelles-Annual assessments.554.29 Cotisations annuelles-Annual assessments.1,519.61 Cotisations annuelles-Annual assessments.4,267.00 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-Joseph.St-Joseph.St-Joseph.St-Joseph.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Joseph.St-Joseph.St-Joseph.St-Joseph.St-Joseph.St-Joseph.St-Joseph.St-Joseph.St-Joseph.00 AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014C ntinued Node\t\t\t\t\t\t\t\t\tNoms des quar- la\tQuartier\tNo du cadastre\t\tNo de la rue\tRue\tPropriétaire cotisé\tMontant\tNature des réclamations\ttiers pour fins cédule\t\t\t\t\t\t\t\t\tmunicipales \u2014\t\u2014\t\u2014\tSubdivision\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014 Sche-\t\t\t\t\t\t\tAmount\t\tNames of wards dule\tWard\tCadastral No.\t\tStreet number\tStreet\tAssessed proprietor\tclaimed\tNature of claims\tfor municipal No.\t\t\t\t\t\t\t\t\tpurposes St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine., St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.Partie de\u2014part of 1021 1031, 1032 partie de\u2014part of 1027 Partie de\u2014part of 1100 Partie de\u2014part of] 1125 Partie de\u2014part of 1130 1181 1184 Partie de\u2014part of 1193 1308 1322 Partie de\u2014part of 1338 1339 1339 70, 72, 74.76, 78, 80 Latour 4, 6, 8, 10 et-and 12 25, 27, 27a 212, 214.216, 218, 220, 222 91a.9iy2 219, 221, 223, 225, 227, 229 425, 427, 431 et-and 435 66, 68 32, 34, 36, 38, 40 58.60 102.104, 106 27 42, 44 51, 51a 30, 30a 28, 2» 26,126a Marie-Louise Martineau et\u2014 and Laura-E.Martineau.Ruelle Busby-Lane Ste-Geneviève.Charles Charters Université\u2014University.John-E.Wright Université-University.Ste-Geneviève.Isabella McRea, épouse de\u2014 wife of Thos.Charles Lids-stone.Montreal Landry Company Limitée\u2014Limited.Alymer.Edward Brophy.Mayor City Councillor.Mayor.City Councillors.Burnside.Victoria.McGill College.Victoria.Victoria.Victoria- Edward Brophy- D.Lome Crawford.703.11 1,729.80 Michael McElhron.Leopold Stern.The Victoria Realty Company, Victor E.Mitchell président\u2014president.The Victoria Realty Company.Victor E.Mitchell, president-president.The Victoria Realty Company, Victor-E.Mithcell, président\u2014president.Cotisations annuelles.Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.389.23 Cotisations annuelles\u2014 J Annual assessments.731.39 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 ¦Annual and special assessments.761.68 25.25 567.20 329.94 20.35 773.36 522.05 625.19 628.11 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales.\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales.Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.00 St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.Sfr-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.1339 1339 Partie de\u2014part of 1405 1424 1456 1457 Partie de\u2014part of 1475 1495 1503 1507 1507 Partie de\u2014part of 1531 Parties de-parta pf 10 et-and 11 1 1 24, 24a 22, 22a, 225 145, 145a 132, 132a 478, 478a, 480, 482, 484 486, 488 1,2 13, 14, 15 Partie de\u2014part of 16 560, 560a 108 40 628 Victoria.Victoria.The Victoria Realty Company.Victor-E.Mitchell, president-president.The Victoria Realty Company, Victor E.Mitchell, président\u2014president.Mansfield.Azarias Lcl>eau.Mansfield.St-Catherine Ouest-West Peel.St-Catherino Ouest-West Stanley.Athalie Leriche.Drummond.St-Catherine ouest\u2014west The Windsor Arcade Limitée, Herbert M.Marier, prés.The City Investment Company of Montreal, Limitée Thomas B.Little et\u2014and Walter Bryson Strachan.Leopold Stern.James H.Maher.Marie E.Adèle Prévost, veuve de\u2014widow of Azarie Brodeur.635 95 707.57 569.27 887.18344.1.816.2,314 1.46.3 -Il 40 Os 72 -T.2,393.29 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles.Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuell \\ 11 : m î : 11 assessments.Cotisations annuelles et spéciales.Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.1,832.30 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-Georges.St-Georges.St-George.s St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-Georges.St-André\u2014 St.Andrew \u2022 SJi,e àiîa subst\"tutlon.c/éée Par le testament de fou Amable Prévost, devant J.Belle.N.P.le 24 décembre 1844.et le codicile du 22 juin 1860.devant ledit notaire et dûment enregistré au bureau d enregistrement pour Montréal-Ouest, le 16 août 1872, sous le No 1661.\u2014Subject to the substitution created by the last will and testament of the late Amable Prévost, before J.Belle.N.P.on the 24th December, 1844.and the codicil of the 22nd June.1860.before the said notary and duly registered in the registrv office for Montreal-West, on the 16th August, 1872, under the No.1661.- ~ 279 |St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.Partie de\u2014part of 1539 1567 1578 Partie de\u2014part of 1582 1626 1628 1628 Parties de\u2014 parts of 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 5 G.7 H.1 365, 367, 371, 373 46 20, 22, 24, 26, 28, 30 293 42 Aqueduc\u2014Aqueduct.Overdale.Crescent.Mackay.St-Marc.William Henry Bell.Anne Duplessis, épouse de\u2014 wife of J.Ain hi nu- Guénette Robert Duncan.David Duncan, Samuel Duncan.John Bennett Briggs et\u2014and John Fair.Les Propriétaires Incorporés.3,193.00 894.80 1.883.88 319.92 2,713.05 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuell \\nnual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St.André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St Andrew.oo en Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Node la cédule Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street dumber Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes 333 St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.370 St-Antoine.1637 1637 1637 1637 1641 1641a 1645 1646 1653 1653 1653 1653 1654 Partie de\u2014part of 1661 28 29 44 11 1 1 .Partie de\u2014part of 22C Partie de\u2014part of 22Z> Partie de\u2014part of 22E 22 F.Partie de\u2014part of 74 403, 403a, 4036, 403c St-Antoine 405, 405a, 4056, 405c 419, 419a et\u2014and 4196 421, 421a et\u2014and 4216 10 37, 39, 41 43, 45 1018a, 1020 1024 1026, 1026a et\u2014and 10266 86 873 St-Antoine.St-Antoine.St-Antoine.Seymour.Sussex.Ste-Catherine ouest-west.Ste-Catherine ouest-west.Ste-Catherine ouest-west.St-Marc.Ste-Catherine ouest-west.Hannah alias Annie Crown, veuve de\u2014widow of Moses Greenberg.usufruitière \u2014 usufructuary.Hannah alias Annie Crown, veuve de\u2014widow of Moses Greenberg, usufruitière \u2014 usufructuary.Marie Eugénie Morin.épouse de\u2014wife of Placide R.Decary.Marie Eugénie Morin, épouse de\u2014wife of Placide R.Décary.Helen Ogilvie Thompson, épouse de\u2014wife of John F.Raphael.William Meikle.Caroline Sophie Barnard, épouse de\u2014wife of John Bennett Briggs.City Estates Limitée, Wm.Geraghty, président.City Estate Limitée, Wm.Geraghty, président.David Duncan.Robinson & Company, Florence Sarah Smith, Isabella Marthe Lane, épouse de\u2014 wife of Horatio Nelson Robinson.299.77 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.299.77 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.172.70 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.172.70 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.272.48 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.538.65 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.494.80 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.524.90 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.1,415.00 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.293.34 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.2,786.55 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-André\u2014 St.Andrew.St-Andre\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.g£ Ci St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew. 377\tSt-Antoine.\tPartie de\u2014part o\t\t453 et\u2014and 465\tGuy.\t\t1686 Partie de\u2014part of 1686a 16866 Partie de\u2014part of 1686c\t\t\t 380\tSt-Antoine.\t1686\t2\t483\t 382\tSt-Antoine.\t1686\t15\t473\t 383\tSt-Antoine.\t1686\t16\t471\t 384\tSt-Antoine.\t1686\t17\t469\t 385\tSt-Antoine.\t1686\t18\t467\tGuy.388\tSt-Antoine.\tPartie de\u2014part of\t\t454, 456 220\tMacKay 390\tSt-Antoine.\t1690 1703\tPartie de\u2014part of 8\t\t 391\tSt-Antoine.\t1703\tParties de-parts of 23 et\u2014and 24\t199\t 393\tSt-Antoine.\t1703\t70\t\tSte-Catherine ouest\u2014 west.\t\t\t\t\t 395\tSt-Antoine.\tParties de \u2014 parts\t\t\tSte-Catherine ouest\u2014 \t\tof 1704 et\u2014and 1705\t\t\twest.414\tSt-Antoine.\t1755\tParties de \u2014\t\tAvenue des Pins ouest\u2014 Pine Avenue west.\t\t\tparts of 57 et \u2014and 58\t\t 416\tSt-Antoine.\tPartie de\u2014part of\t\t313\t \t\t1768\t\t\t The West End Land and Improvement Company Limitée\u2014Limited.Robert Dunean.The West End Land and Improvement Company Limitée\u2014Limited.The West End Land and Improvement Company Limitée\u2014Limited.The West End Land and Improvement Company Limitée\u2014Limited.The West End Land and Improvement Company Limitée\u2014Limited.Ethel Reaburn Mclntyre, épouse de\u2014wife of Walter H.Ewing.Charles L.Shorey.Sarah S.Holland, veuve de\u2014 widow of Charles A.Briggs.James H.Maher.O'Gilvy Realties Limitée\u2014Limited .Howard C.Stone.Charles A.Barnard.9.705.15 347.46 443.59 440.43 430.88 447.06 811.54 1,273.32 803.90 1,885.26 15,089.20 331.89 890.18 Cotisations annuellcs-Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles-Annual assessments.Cotisations annuelles Annual assessments.Cotisations annuelles Annual assessments.Cotisations annuelles Annual assessments.Cotisations annuelles-Annual assessments.Cot isations annuell Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Animal and s|H'cial assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.( ntisations annuelles\u2014 Animal assessments.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-André\u2014 St.Andrew.St-Georges.St-Georges. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Node 1* cédule Schedule No.\tQuartier\tNo du'oadaatre\tSubdivision \tWard\tCadastral No.\t 423\tSt-Antoine.\tPartie de\u2014part of\t \t\t18415\t 429\tSt-Laurent\u2014 St.Lawrence.\t2\t6 441\tSt-Laurent\u2014 St.Lawrence.\t16a\t17 447\tSt-Laurent\u2014 St.Lawrence.\t19\t926 464\tSt-Laurent\u2014 St.Lawrence.\t19\t118 465\tSt-Laurent\u2014 St.Lawrence.\t19\t119 466\tSt-Laurent\u2014 St.Lawrence.\t19\t120 467\tSt-Laurent\u2014 St.Lawrence.\t19\t121 468\tSt-Laurent\u2014 St.Lawrence.\t19\t122 474\tSt-Laurent\u2014 St.Lawrence.\t42\tPartie de\u2014part of 4 478\tSt-Laurent\u2014 St.Lawrence.St.Lawrence.\t43\tParties de-parts of 46 et-and 47 479\tSt-Laurent\u2014 St.Lawrence.\t43\t61 No de la rue Street number Rue Street 78 209,211,213,215, 217, 219, 221, 223, 225,227, 229.231, 233, 235, et-and 237 1032, 1034 735 916, 918 920, 922 924, 926 \u2022 928, 930 932 4, 6, 8 621 400, 402 et-and 404 268,270 et-and 272 Avenue des Pins Ouest-Pine Ave West.Boulevard St-Laurent-St.Lawrence Blvd.Durocher.St-Urbain.Boulevard St-Laurent\u2014' St.Lawrence Blvd.Boulevard St-Laurent-St.Lawrence Blvd.Boulevard St-Laurent-St.Lawrence Blvd.Boulevard St-Laurent-St.Lawrence Blvd.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Blvd.Guilbault.Ste-Famille- Jeanne-Mance.Jeanne-Mance.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes 'Wilfrid Bovey.Albertine Laurendeau, épouse, de\u2014wife of Frédéric Alfred Lallcmand.478.40 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.1,510.89 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Abraham Schwartz.William Charles Maxwell Moses JacobGlickman, Tobias Glickman.Philip Glickman Philip B.Glickman.Morris Joseph et\u2014and Adolphe Leibovitz.Joseph-C.Groves Contant.Blanche Robinson, veuve de-j- | widow of Napoléon Robi-tailla.Hannah alias Annie Crown, 1 veuve de\u2014widow of Mosesj Greenberg, usufruitière\u2014i usufructuary.360.34 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.162.28 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.416.15 Cotisatilonsannuelles Annual assessments.416.15 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.413.77 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.415.35 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.549.97 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.163.82 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.425.78 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.376.13 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-Georges.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence. 480 487 489 497 503 504 507 513 527 532 536 537 538 539 548 555 St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.43 47 48 48 70 115 115 118 168 168 Parties de\u2014Parts of 188 et-and 189 206 Partie de\u2014part of 217 Partie de\u2014part of 217 Partie de\u2014part of 217 Partie de\u2014part of 217 252 266, 267 62 4, 5, 6 7, 29 Parties de-parts of 8 et-and 9 1 4 19 29 Partie de\u2014part of 30 10 et-and 14 274, 276 et-and 278 186, 188 171 12 et-and 14 729 717 11, 13 548 2, 4, 6, 8, 10, 12 422, 424, 426, 428, 434, 436, 438,440 et-and 442 51 137 et\u2014and 139 141 et\u2014and 143 145 et-and 147 149 et\u2014and 151 22 365 32 et-and 34 95.113 et\u2014and 129 Jeanne Mancc.Hutchison.Hutchison.Ste-Famille.Clarke.Clarke.Milton.St-Urbain.Concord.Bleury.Mayor.St-Alexandre.St-Alexandre.St-Alexandre.St-Alexandre.Mayor.Bleury.Balmoral.Ste-Catherine ouest west.Hannah alias Annie Crown, veuve de\u2014widow of Moses Greenberg usufruitière\u2014 usufructuary.Ada Coussirat.Eva Coussirat, épouse de-wife of Théophile-Auguste A.Reeb.Charles Atkinson Wilson.Julia Clifford, épouse de-wife of William Meikle.Julia Clifford épouse de-wife of William Meikle.The Talmud Torah Anshe Saford, Lewis Solomon, président\u2014president.Joseph Steinberg.Joseph A.Caron et\u2014and and Adolphe-L.Caron.William Meikle.Corner Realties Limitée\u2014 Limited.Corner Realties Limitée\u2014 Limited.Corner Realties Limitée\u2014 Limited.Corner Realties Limitée\u2014 Limited.James-E.Wilder.Nazareth Property Limitée-Limited.250.53 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.421.40 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.257.13 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.470.77 ( 'otisations annuelles\u2014 Annual assessments.147.88 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.137.66 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.231.18 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.276.42 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.5,050.79 Cotisations annuell Annual assessments 1,265.19 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.421.60 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.427.98 Cotisations annuelles\u2014 \\nnual assessments\u2014.432.7* Cotisations annuelh?s\u2014 Annual assessments.1,731.45 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.5,111.90 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments' 1,048.18'Cotisations annuelles et spéciales-| Annual and special assessments.I St-I-aurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lzwrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-I-aurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IM MOVEABLES\u2014Continued Node la cédule Schedule No.\tQuartier Ward\tNo du cadastre Cadastral No.\tSubdivision\tNo de la rue Street number\tRue Street\tPropriétaire cotisé Assessed proprietor\tMontant Amount claimed\tNature des réclamations Nature of claims\tNoms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal put poses 561\tSt-Laurent\u2014 St.Lawrence.\t324\t\t21, 23, 25.27 360 et\u2014and 362\tDemontigny ouest\u2014west.Clarke.\tJoseph Henri Skelly\t432.80\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.\tSt-Laurent\u2014 St.Lawrence.\t\t\t\t\t\t\t\t\t Sujet à la substitution créée par le testament de James Skelly.devante.F.Papineau, N.P., le 26 février 1885, et dûment enregistré au bureau d'enregistrement pour Montréal-Est.le 4 mai 1885, sous le No 14187.\u2014Subject to the substitution created by the last will and testament of James Skelly, before C.F.Papineau, N.P., on the 26th February, 1885.and duly registered in the registry office for Montreal East, on the 4th May, 1885, under the No.14187.680 [St-Laurent\u2014 Partie de\u2014part of St.Lawrence.423 St-Laurent\u2014 St.Lawrence.433 Partie de\u2014part of 448 21, 23.23a 20, 22 Vallée.Vallée.Abraham M.Rosenbaum.The University Realty Company Limitée\u2014Limited.8.16 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.820.85 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.jSt-Laurent\u2014 'St.Lawrence.St-Laurent\u2014 lSt.Lawrence.S Sujet à la substitution créée par le testament de John Whalen, devant J.Lonergan, N.P., le 16 mai 1883.et dûment enregistré au bureau d'enregistrement pour Montréal-Est, le 9 janvier 1885, sous le No 13570.\u2014Subject to the substitution created by the last will and testament of John Whalen, before J.Lonergan, N.P., on the 16th May, 1883.and duly registered in the registry office for Montreal East, on the 9th January, 1885, under the No.13570.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.Partie de\u2014part of 469 470 471 472 Partie de\u2014part of 503 505 512 \t322, 324, 326, 328 334, 336 et\u2014and 338 \t \t340, 342 et\u2014and 344 168, 170 et\u2014and 172 2, 10, 12 168, 170 et\u2014and 172 31 \t \t \t St-George.St-George.St-George.St-George.Bleury.Carmichael Bleury.Dowd.Fred W.Stair Fred W.Stair.Fred W.Stair Fred W.Stair Bleury Investment Company Limitée\u2014Limited.Bleury Investment Company Limi t ée\u2014Li mi ted.Charles Stewart Babcock.485.67 445 31 94.90 1,412.02 1,637.17 864.11 519.97 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessment.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent.St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St- Lawrence.St-Laurent\u2014 x \u2022 Lawrence.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments. 599 600 608 609 611 614 615 617 621 624 St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.631 St-Laurent\u2014 St.Lawrence.633 S t-Louis.636 S t-Louis.532 Partie de\u2014part of 532 557 Partie de\u2014part of 613 Parties de\u2014Parts of 615 et-and 616 Parties de\u2014Parts of 629 et-and 630 Partie de\u2014part of 652a Partie de\u2014part of 664 674 710 729 Parties de\u2014Parts of 819 et-and 829 19 Partie de\u2014part of 26 107, 109, 111, 113 Bleury.169, 171, 173, 175 et\u2014and Lap;aucheticre ouest\u2014 west.Abraham Sommer.177 86, 88, 88a, 885, 90, 92 135.137, 139, 141, 143, 145 220, 222, 224, 226 204.206, 208, 210 et\u2014and 212 1, 3 120 112 100.102.104.106 1.3, 5, 5K, 7, lYt, 9, 9a 11, 13, 15, 17 1, 3, 5 27, 27a 68, 70 58, 60, 62, 64 52, 54, 56, 58 et-and 60 66, 68 9.9a, 11 10 et\u2014and 10a 16 et\u2014and 16a Chenneville.Clarke.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Blvd.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Blvd.Vitré, Ouest-West.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Blvd.St-Urbain.St-Georges.Des Jurés\u2014Jurors.Des Jurés\u2014Jurors.Anderson.St-Alexandre.Des Jurés\u2014Jurors.Des Jurés\u2014Jurors.Hermine.Boulevard St-Laurent- St.Lawrence Blvd.Clarke.Sanguinet.St-Elizabeth.Hermine Alain, épouse de widow of Charles Edmond Ranger.The Northern Fur Manufacturing Company, Limitée-Limited.Lazarus Millman.Max Gross et\u2014and Joseph Zehne.Joseph Alex.Besner et\u2014and Aron Block.Alexander Roy McDonald.Margaret Bronder, épouse de wife of Michael Delahanty, usufruitière\u2014usufructuary.Margaret Bronder, épouse de-wife of Michael Delahanty, usufruitière\u2014usufructuary.Maurice Biais.Elizabeth Rice, veuve de\u2014 widow of Thomas Buchanan, usufruitière\u2014usufructuary.Joseph Alexander Besner, Samuel Berlind.Deeb E.Deeb.Romuald A.Bernier ct\u2014and Albina Deschamps.2,245.77 sss ry.i 2,850.83 3,557.28 20.84 322.22 692.65 554.83 481.68 25.87 1,481.38 263.117.92 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Sjjecial assessments.Cotisations annuelles et si>éciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Sujet à la substitution créée par le testament olographe de Remi Hilaire Bernier, le 16ième jour de mai 1908, et.dûment enregistré au bureau d'enregistrement pour 6ème jour de février 1909, sous le No 74094.\u2014Subject to the substitution created by the holograph will of Remi Hilaire Bernier, on the 16th dav of May, 1908, and dulv registry office, for Montreal-East -, on the 6th day of February, 1909, under the No.74094.640 iSt-Louis.50 et-and 51 79, 81, 83 et\u2014and 85|St-Dominique.[Isaac Miller.i 133.74.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 32, 34, 36 et\u2014and 38 ISte-Agathe.Annual and special assessments.St-Laurent.St.Lawrence.St-Laurent.St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Laurent\u2014 St.Lawrence.St-Louis.St-Louis.Montréal-Est, le registered in the I St-Louis. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Node la cédule Schedule No.Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Piopriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Natuie des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes 643 St-Louis.651 St-Louis.Partie de\u2014part of 118 85 14 121 Lagauchetière.Congregation Beth Judah de Montréal.Cadieuz.Alphonse Lamoureux.176.38 Cotisations annuelles et special Annual and special assessments.15.13 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.St-Louis.St-Louis.Sujet à la substitution créée par le testament de Henriette Gonon, épouse de Eugène Lamoureux.devant F.Rieutord, notaire, le 9ème jour de Mai 1884, et dûment enregistré au bureau d'enregistrement pour Montréal-Est, le 21ème jour de décembre 1888, sous le No 22441 et à la substitution créée par le testament de Eugène Lamoureux, devant F.Rieutord, notaire, le 28 juillet 1884 et dûment enregistré au bureau d'enregistrement pour Montréal-Est, le 9 octobre 1889 sous le No 24431.\u2014Subject to the substitution created by the last will and testament of Henriette Genon, wife of Eugène Lamoureux, before F.Rieutord, notary, on the 9th day of May, 1884, and duly registered in the registry office for Montreal-East, on the 21st day of December, 1888, under the No.22441, and to the substitution created by the last will and testament of Eugène Lamoureux, before F.Rieutord, notary, on the 28th July, 1884, and duly registered in the registry office for Montreal-East, on the 9th October, under the No.24431 652 ! St-Louis.[Partie de\u2014part ofl 118 J 127 ICadieux.(Succession\u2014Estate I I Lamoureux.Amédéel 111.88[Coti8ations annuelles\u2014 JAnnual assessments.J St-Louis.654 666 St-Louis.St-Louis.Sujet à la substitution créée par le testament de Henriette Genon, épouse de Eugène Lamoureux, devant F.Rieutord, notaire, le 9 mai 1»-S4 et dûment enregistré au bureau d'enre- fcO gist rement pour Montréal-Est, le 21 décembre 1888 sous le No 22441 et à la substitution créée par le testament de Eugène Lamoureux, devant F.Rieutord, N.P., le 28 juillet 1884 et dûment enregistré au bureau d'enregistrement pour Montréal-Est, le 9 octobre 1889 sous le No 24431.\u2014;Subject to the substitution created by the last will and testament of Henriette Genon, wife of Eugène Lamoureux, before F.Rieutord, notary, on the 9th May, 1884, and duly registered in the registry office for Montreal-East, on the 21st December, 1888, under the No.22441, and to the substitution created by the last will and testament of Eugène Lamoureux, before F.Rieutord, N.P., on the 28th July, 1884, and duly registered in the registry office, for Montreal-East, on the 9th October, 1889, under the No.24431.Partie de\u2014part of 121 Partie depart of 160 76 65 Avenue de l'Hôtel-de-Ville Sanguinet.Isaac Kander, Edith Frank, épouse de\u2014wife of Hyman J.Eliasoph.Thadée Villeneuve.124.98Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.106.^Cotisations annuelles\u2014 (Annual assessments.St-Louis.St-Louis.Sujet à la substitution créée par la donation faita par Marie-Mélanie Durand, épouse de Nazairc Villeneuve, devant L.-J.-O.Hétu, N.-P., le 1er juin 1887 et dûment enregistrée au bureau d'enregistrement pour Montréal-Est, le 15 juin 1887, sous le No 18544.\u2014Subject to the substitution created by the donation, made by Marie-Mélanie Durand, wife of Nazaire Villeneuve, before L.-J.-O.Hétu, N.P., on the 1st June, 1887, and duly registered in the registry' office for Montreal-East, on the 15th June, 1887, under the No.18544.672 680 |St-Louis.St-Louis.Partie de\u2014 part of 212 Partie de\u2014 part of 280 157a, 1576, 157c, 157d.159 et\u2014and 159a 354, 356 et\u2014and 358 Hôtel-de-Ville.St-Dominique .Alphonse Lemoyne DeMarti-gny.Max Boronow.271.56jCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.288.16Cotisations annuelles\u2014 |Annual assessments.(St-Louis.St-Louis. St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.281 308 348 347 368 362 413 431 443 479 528 537 et\u2014and 538 540 560 566 327 et\u2014and 329 290, 292.296, 298 et\u2014and 300 2, 4, 6, 8, 10, 12 et-and 14 221.223, 225.227 et\u2014and 229 94, 96, 98 et\u2014and 100 132, 134 137 et\u2014and 137a 25 296 199, 201, 203 et\u2014and 205 156 et\u2014and 158 384 et\u2014and 386 1, 3.5, 7, 9.11 381, 383, 385, 387, 389,391 380, 382, 384, 386, 388, 390 401, 403, 405 et\u2014and 407 398 491, 493, 495.497 et\u2014and 499 18, 20, 22, 24 441, 443, 445, 447 et\u2014and 449 21, 23 et\u2014and 25 St-Laurent-St.Lawrence.Max Boronow Cadieux.Charlotte.Hôtel-de-Ville.St-Elizabeth.Ste-Elizabeth.Sanguinot et\u2014and Ste-Julie.Ste-Catherine est\u2014east.Sanguinot.Demontignyest\u2014east.Cadieux.Ste-Catherine est\u2014east.St-Laurent-St.Lawrence.St-Dominique.St-Laurent-St.Lawrence.St-Dominique.St-Dominique et \u2014 and Ruelle Grubert\u2014G rube rt Lane.St-Dominique et\u2014and Demontigny est\u2014east.Morris Jaslow.Grégoire Rochon Joseph Roger Lesage.Edgar Tremblay.Ucal H.Dandurand.Claire Roy, Aurise Roy et-and Julie Roy.Sarah Shapiro, épouse de-wife of Morris Muller.Annette Maillet, veuve de-widow of Rodolphe Jules Demers.Succession \u2014 Estate Pierre Edmond Paquette, Albina Carrière, veuve de\u2014widow of Pierre Edmond Paquette, Edmond J.Paquette, Roméo Paquette, Adrien Auguste Paquette, Annon-ciade Paquette, épouse de\u2014 wife of John C.Brennan.Albina Paquette, épouse de \u2014wife of James Tellier, Florianne Paquette, épouse de\u2014wife of Hector Racine.Aaron Poyaner et\u2014and Myer Poyaner.Marcus Hersh Schaehter.Anna Caplan, épouse de\u2014 wife of Joe Levin.933.20|Cotisations annuelles.Annual assessments.969.46 183.58 260.51 11,201.39 258.40 424.76 1,356.37 9,597.15 1,299.11 12.26 11.47 Cotisations annuelles et spéciales Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annua! assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis\u2014 1,191.62 Cotisations annuelles-Annual assessments. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Node la cédule Schedule No.Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprieto.- Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims (Noms des quartiers pour fins I municipales I Names of waida I for municipal I purposes 743 746 749 756 768 769 771 804 805 806 808 809 810 St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.568 581a 594 625, 626 et-and 627 685 686 701 782 783 Partie de\u2014part of 785 788 789 790 29, 29a.31, 31a.33, 35, 37 et\u2014and 39 498.500.502.504 et\u2014and 506 547, 549 et\u2014and 551 441, 441a, 4416, 443 et-and 443a 252, 254, 256, 256H.260, 260a 262, 262a et-and 264 264, 264a et-and 266 265, 267 et\u2014and 269 594, 596, 598 et\u2014and 600 586, 588, 590 et-and 592 570, 572.574 571.573.573a 583, 585, 587 589, 591, 593 et-and 595 597, 599, 599a, 601 et-and 603 Demontignyest\u2014east.Cadieux.Cadieux.Hôtel-de-Ville.':.Sanguinet.Sanguinet.Demontigny Est-East.St-Dominique.Michel Rchachter, Benjamin Schachter.Louis Schachter, Aron Schachter.Ida Schachter et\u2014and Nathan Schachter.Abraham Rudner et\u2014and Joseph Rudner.St-Dominique.St-Dominique.St-Laurent-St.Lawrence.St-Laurent-St.Lawrence.St-Laurent-St.Lawrence St-Laurent-St.Lawrence Harry Cohen.Delle Lena Letzter.Camille Jutras et\u2014and Emile Jutras.Camille Jutras et-and Emile Jutras.Claire Roy, Julie Roy et-and Aurise Roy.John L.Eaves et-and Leah Gross, épouse de\u2014wife of Jacob Lecker.Virgina Gibouleau.Abel Wollenberg.Virgina Gibouleau.Virgina Gibouleau.Virgina Gibouleau.718.25 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.455.72 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.42.77 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.423.39 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.24.08 Cotisations spéciales.\u2014 Special assessments.13.80 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.474.26 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.131.74 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.145.81 Cotisations annuelles-Annual assessments.1,218.70 Cotisations annuelles-Annual assessments.434.97 Cotisations annuelles-Annual assessments.418.62 Cotisations annuclles-Annual assessments.449.98 Cotisations annuelles-Annual assessments.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis. 811 St-Louis.f Partie de\u2014part of' 791 824 846 851 866 875 880 883 884 887 888 889 890 891 895 St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.825 Partie de\u2014part of 893 897 902 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 Partie de\u2014Part of 13 29 Partie de\u2014Part of 44 159 201 202 215 et-and 216 Partie de\u2014Part of 219 220 221 222 232 et-and 233 104.106.10S.110.112.114, 116.118 et-and 120 605, 607 et\u2014and 609 791 et\u2014and 793 26 et\u2014and 28 634.636 et-and 638 661 450 et-and 452 101.101a et-and 1016 136, 136a et-and 1366 603d et\u2014and 603< 603/ et\u2014and 603a 634 et\u2014and 636 614 et\u2014and 614a 612 et\u2014and 612a 610 et\u2014and 610a 608 et\u2014and 608a 586 et-and 588 St-Norbert St-Laurent.St-Dominique Prince-Arthur Hôtel-de-Ville Hôtel-de-Ville Henri Julien Drolet.Drolet.Henri Julien Henri Julien Henri Julien Henri Julien Henri Julien Henri Julien Henri Julien Henri Julien John L.Eaves et-and Leah Gross, 0|>ouse de \u2014wife of Jacob Lecker.Esther Malkie Dupps, veuve de\u2014widow of Helman Cohen, Tobie Cohen,épouse de \u2014wife of Saul Richstone, Peikei Cohen, épouse de wife of Ansel I Goldsmith, Harry Cohen, Israel Richstone, Julius Cohen, Samuel Cohen, David Cohen et-and Jacob Cohen.Abraham Szolvich.Marks Magcd.Damien Masson et\u2014and Eugene St-Jacques.Auguste Dufresne, Thomas Jacques Dufresne, Georges Henri Dufresne et\u2014and Pierre Dufresne.Robert Lalonde.Isidore Greenblatt.Isidore Greenblatt.Israel Lemieux.Israel Lemieux.Israel Lemeiux.Israel Lemieux.Isreal Lemieux.The Sapho Manufacturing Company.Limitée.-Limited 1,197.37 Cotisations annuelles-Annual assessments.456 30 10.21 154 50 176.14 11.85 121.22 86.3 96.92 109.11 89.63 89.62 89.63 89.63 309.21 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales.Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales.Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales-Annuul and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessnemts.Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IM MOVEABLES\u2014Continued Node la cédule Quartier Ward No du cadastre CadasUal No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of daims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.St-Louis.915 921 922 Partie de\u2014part of 926 Partie de\u2014part of 930 939 980 1024 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049 Parties de-parts of 6 et\u2014and 7 3 1 13 1 2 16 17 18 19 21 Partie de\u2014Part of 22 790 et\u2014and 792 92 910, 910a et\u2014and 9106 1117 367, 369.369a.371, 371a et-and 373 1074 et\u2014and 1076 901 et\u2014and 903 1035a, 1037 et-and 1039 1125, 1127 et-and 1129 1061 et\u2014and 1063 1057 et\u2014and 1059 1053 et\u2014and 1055 1049 et\u2014and 1051 1041 et\u2014and 1043 1037 et-and 1039 Hôtel-de-Ville.Ave des Pins\u2014Pine Ave.Hôtel-de-Ville.Cadieux.Coloniale.Cadieux.St-Dominique.St-Laurent-St.Lawrence.St-Dominique.St-Dominique.St.-Dominique.St-Dominique.St-Dominique.St-Dominique.Morris Rasminsky Abraham Schneer.Moses Blitz et-and Isaac Ko-lomier.Hattie Levin veuve de\u2014 widow of Bernard Levin.Morris Chait et\u2014and Bonnie Fisher.Ernest Rahow.Abraham Rudner et\u2014and Isidore Greenblatt.Dora Vachtman.épouse de wife of Samuel Bercuson.Abraham Hahomovitch et\u2014 and Hyman Charles Seigler.Abraham Hahomovitch et\u2014 and Hyman Charles Seigler.Abraham Hahomovitch et\u2014 and Hyman Chartes Seigler.St-Dominique.Abraham Hahomovitch et\u2014 and Hyman Charles Seigler.Billey Cohen et\u2014and Skeka Cohen, épouse de\u2014wife of Slaman Kamashear.Billey Cohen et\u2014and Skeka Cohen, épouse de\u2014wife of Slaman Kamashear.398.12 Cotisations annuelles\u2014 ISt-Louis.Annual assessments.11 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 St-Louis.Annual and special assessments.6.20 Cotisations spéciales\u2014 St-Louis.Special assessments.11.53 Cotisations sépciales\u2014 St-Louis.Special assessments.159.33 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 St-Louis.Annual and special assessments.249.04 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 St-Louis.Annual and special assessments.319.99 Cotisations annuelles\u2014 St-Louis.Annual assessments.39.65 Cotisations spéciales\u2014 St-Louis.Special assessments.118.23 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 St-Louis.Annual and special assessments.118.25 Cotisations annuelles et spéciales.\u2014 St-Louis.Annual and special assessments.118.24 Cotisations annuelles et s|>éciales\u2014 St-Louis.Annual and special assessments.118.26 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 St-Louis.Annual and si>ecial assessments.132.39 Cotisations annuelles\u2014 St-Louis.Annual assessments.132.39 Cotisations annuelles\u2014 St-Louis.Annual assessments. St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacquea\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques St.James.St-Jacques-St.James.St-Jacques-St.James.73 173 216 Partie de\u2014part of 315 Partie de\u2014part of 326 372 431 432 432 522 530 537 26 2 partie de \u2014 part of 2 Partie de\u2014part of 3 18, 20, 22 355a, 355c et\u2014and 357 133 99.101, 103.105.107.109 647, 649.651.653 590.592, 594.596 et\u2014and 598 160.162 319, 321 et\u2014and 323 125, 127 et\u2014and 129 2, 4, 6, 8 400.402.404, 406.408, 410 412, 414, 416, 418, 420 422, 424 256, 280 et\u2014and 282 243 205, 207 et\u2014and 209 470, 472, 474, 476, 478, 480 et\u2014and 482 249 Montcalm.St-Louis.\u2022 Berri.Montcalm.Craig est\u2014east.Dorchester est\u2014east.Montcalm.Lagaucheticre est\u2014east.St-Denis.Notre-Dame-de-Lourdes .Ste-Catherine est\u2014east.St-Christophe.St-Hulwrt.St-Christophe.Ste-Catherine est\u2014east.St-André\u2014St.Andrew- Bertha A.Seh worse nsky.épouse de\u2014wife of Osias L.Korner.Napoléon Mathieu.Ernest Abdel nour.Edouard Jolin.Marie Champagne, veuve de \u2014widow of Emile Berthiau-me, usufruitière\u2014usufructuary.Joseph Lorange usufruitier-usufructuary.J.Emile Léonard, Rose Ga-boury.épouse de\u2014wife of J.Wilfrid Lavoie.Midland Investment Company Limitée\u2014Limited.U.Henri Dandurand.Napoléon Fafard.Succession \u2014 Estate Louis Raymond Plcssis dit Belair.9.17 9.70 291.75 9.15 222.79 17.5', 372.84 1,089.34 5,436.88 109.60 3,686.28 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-Jacquea\u2014 St.James.St-Jacqui St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacqui St.James.St-Jacquea\u2014 St.James.St-Jacque St.James.St-Jacqu St.James.St-Jacquea\u2014 St.James.St-Jacques.St.James.Sujet à la substitution créée par le testament de Louis R.Plessis dit Bélair, devant L.S.Martin, N.P., le 26 juillet 1840, et le codic.ile du 9 septembre 1845, devant ledit notaire, et dûment enregistré au bureau d'enregistrement pour Montréal-Est, le 9 mai 1889, sous le No 23359.\u2014Subject to the substitution created by the last will and testament of Louis R.Plessis dit Bélair, before L.S.Martin, N.P., on the 26th July, 1840, and the codicil of the 9th September.IS 15, before the said notarv, and duly registered in the registry office for Montreal-East, on the 9th May, 1889, under the No.23359.St-Jacques\u2014 St.James.547 471.473, 475,477 Dorchester est\u2014east.Marie Eugénie Duhamel.578.42 Cotisations annuelles-Annual assessments.St-Jacques\u2014 St.James. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IM MOVEABLES\u2014Continued Node la cédule Schedule No.Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Sujet à la substitution créée par le testament de Joseph Duhamel, devant Théodore Doucet, N.P., le 12 octobre 1894, et dûment enregistré au bureau d'enregistrement pour Montréal-Est, le 22 janvier 1895, sous le No 38096.\u2014Subject to the substitution created by the last will and testament Joseph Duhamel, before Théodore Doucet, N.P., on the 12th October, 1894, ai.d duly registered in the registry office for Montreal-East, on the 22nd January, 1895, under the No.38096.1037 1042 1043 1044 St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James Partie de\u2014part of 569 Partie de\u2014part of 583 Parties de\u2014parts of 584 et\u2014and 585 Partie de\u2014part of 593 168, 170, 172, 174, 176, 178 193, 195, 197, 199 et\u2014and 199a 183.183a, 1836.183c.183d.183« et\u2014and 183/.185.187.189 et\u2014and 191 232, 234, 236, 238 Amherst Amherst Amherst Wolfe.Rose de Lima Vezeau, épouse de\u2014wife of Joseph A.Dagenais.Olivier Dubois.Olivier Dubois.Succession \u2014 Estate Amédée Lamoureux.357.33 348.65 1,622.01 189.50 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques St.James.oc S 00 Sujet à la substitution créée par le testament d'Henriettte Genon, épouse d'Eugène Lamoureux, devant F.Rieutord, N.P., le 9 mai 1884.et dûment enregistré nu bureau d'enregistrement pour Montréal-Est, le 21 décembre 1888, sous le No 22441, et par le testament d'Eugène Lamoureux, devant F.Rieutord, N.P., le 28 juillet 1884, et dûment enregistré au bureau d'enregistrement pour Montréal-Est.le 9 octobre 1889, sous le No 24431.\u2014Subject to the substitution created by the last will and testament of Henriette Genon, wife of Eugène Lamoureux, before F.R.Rieutord, N.P., on the 9th May, 1884, and duly registered, in the registry office for Montreal-East, on the 21st December, 1888.under the No.22441.and by the last will and testament of Eugène Lamoureux, before F.Rieutord, N.P., on the 28th July, 1884, and duly registered, in the registry office for Montreal-East, on the 9th October, 1889, under the No.24431.1045 1046 1051 1052 St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.595 Partie de\u2014part of 596 Partie de\u2014part of 596 631 632 246, 248, 248a, 250, 252, 252a, 254, 256 et\u2014and 256a.258, 258a et\u2014and 260 622, 624 257, 259, 261, 263a, 2636, 263c, 263d, 263e, 265, 267.269 Wolfe.Wolfe.Ste-Catherine est\u2014east.Montcalm.Olivier Dubois.Olivier Dubois.Léon Ernest Ouimet Léon Ernest Ouimet.641.12 152.33 2,628 42 303.21 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Ahnual and special assessments.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.Cotisations annuelles'\u2014 Annual assessments. \u2022St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.638 706, 707 Partie de\u2014part of 764 239 311, 311a, 311b.311c.313, 313a.313b.313c.315, 315a, 315b, 315c 569 Montcalm.Beaudry.Ste-Catherine est\u2014east.Joseph Roljert.Edmond D.Porcheron.Berthe Bruneau.76.35 363.98 1.351.01 Cotisations annuelles et special Annual and special assessments Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.Sujet à la substitution créée par le testament d'Esprit A.Généreux, devant N.Pérodeau, N.P., le 28 novembre 1900, et dûment enregistré au bureau d'enregistrement pour Montréal-Est, le 28 juin 1902, sous le No 58086.\u2014Subject to the substitution created by the last will and testament of Esprit A.Généreux, before N.Pérodeau, N.P., on the 28th November, 1900, and duly registered in the registry office for Montreal-East, on the 28th June, 1902, under the No.58086.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.Partie de\u2014part of 824 846 849 849 912 913 918 974 974 974 981 1154 1165 Partie de\u2014Part of 16 41 Partie de\u2014Part of 42 110, 111 112, 113 135, 136, 137 2 5, 6 269, 269a 484, 486 396, 398, 400, 402, 402a.402b 468, 470 et-and 472 474.476 510.512.514.516 et\u2014and 518 438,440 434,436 433, 435, 437, 439, 441, 443 386, 388, 390, 392 642, 644 et-and 646 540.542, 544, 546, 548, 550 608, 610, 612, 614, 616 St-Denis.St-Hubert.St-Christophe.St-Tbimothée.St-Thimothée.St-Thimothée.Wolfe.Wolfe.Wolfe.Montcalm.Montcalm.Sherbooke-Est-East.Amherst.Avila Raymond.Philippe-R.Thomas.Marie- Délima Léda Tremblay, épouse de\u2014wife of Jos.-Edouard Lortie, Marie-Lse Corinne Gratton.épouse de wife of Joseph I.éon Oscar Laurent dit Lortie.Jos.-Anselme Labrecque.Jos.-Anselme Labrecque.J.-M.-A.Laçasse Rousseau.Joseph Betournay.Joseph Betournay.Joseph Betournay.Jean-Bte Tétreault.Harry Pickleman.Félix Dansereau.Il 439.87 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.32 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.273.38 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.119.82 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.131.76 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.213.00 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.146.84 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.137.94.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.281.47 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.146.85 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.131.33 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.160.96 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Lafontaine.La fontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.00 CO St-Jacquea\u2014 St.James. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued No de la cédule Schedule Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue 8treet St-Chri8tophe.St-Christophe.St-André.Providence.Sherbrooke Est-East.Sherbrooke Est-East.Sherbrooke Est-East.Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes 1137 1138 1141 1144 1147 1148 1148a 1149 1150 1151 1152 St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacqu St.James.St-Jacques\u2014 St.James.1193 1193 1193 1193 1195 1198 1195 1196 1196 Partie de\u2014part 1195 1195 1198 of 1198 1198 1196 1197 1198 15.16 21 28 Partie de\u2014Part of 27 156 Parties de-parts of 23 et-and 24 Partie de\u2014Part of 1 Partie de\u2014 Part of 25 637.639.641.643.645, 647.649,651 595.597 514, 516, 518, 520, 522, 524 10 364, 366 et-and 368 352,354 356 361,363 357, 359 353, 355 370,372 Ontario Est-East.Ontario Estr-East.Ontario Est\u2014East- Albert deMun.Marie Champagne, veuve de- 225.01 Cotisations annuel! widow of Emile Berthiaume Annual assessments.Charles Bernier.Joseph Anselme Labrecque.La Compagnie de Coastruc-tion Lafontaine Incorporée, A.-P.Frigon, president.Marie Louise Fortin, veuve de \u2014wife of Horace Dufort.William James Dérome.La Société de Constructi Lafontaine.Duncan L.Lafontaine, Dou glass L.Lafontaine, Cora A Lafontaine et\u2014and Ada L.Lafontaine.Duncan L.Lafontaine, Douglass L.Lafontaine, Cora A.Lafontaine et\u2014and Ada L.Lafontaine.Duncan L.Lafontaine, Douglass L.Lafontaine, Cora A.Lafontaine et\u2014and Ada L.Lafontaine.Simon Garber.T 17.35 434.47 120.88 636.11 2,919.40 on 2,989 194.9: Cotisations spécial Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles-Annual assessments.Cotisations annuelles-Annual assessments.Cotisations annuelles-Annual assessments.23Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.209.80 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.506.84 126.93 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuel les\u2014 Annual assessments.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.^ Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine. 1 163 jSt-Jacques\u2014 jSt.James.1164 St-Jacquea\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.1197 1198 1198 Partie de\u2014part of 1199 1197 1199 1199 1202 1202 1203 3 18 31 16 1, 2 Partie de-of 3 -part 109 Partie de\u2014part of 108 36, 37 366, 368 333, 335 329, 331 334 103, 105 et\u2014and 105a 620, 622, 624 349, 351 Albert de M un.Ontario est\u2014east.Ontario est\u2014east.Sherbrooke est\u2014east Rivard.Berri.Roy est\u2014east.Simon Garber.Olivier Dubois et\u2014and Julie Dubois.J.-B.Baillaigeon Express Limitée.\u2014Limited.Ucal Henri Dandurand.Morris Nueman.Joseph Henri Skelly.134.88 248.60 248.44 1,317.07 193.34 215.89 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual asssesments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Sujet à la substitution créée par le testament de James Skelly, devant C.F.Papineau, N.P., le 26 février 1885, et dûment enregistré au bureau d'enregistrement pour Montréal-Est, le 4 mai 1885, sous le No 14187.\u2014Subject to the substitution created by the last will and testament of James S.Kelly, before C.F.Papineau, N.P., on the 26th February, 1885 and duly registered in the registry office for Montreal-East, on the 4th May, 1885, under the No.14187.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.St-Jacques\u2014 St.James.1203 1207 1207 1207 1207 1207 1211 1211 1211 307 59 Partie de\u2014part of 94 119 167 212 20 36 103 799, 801 et\u2014and 803 826, 828 835, 837 et\u2014and 869 747, 749 473, 475, 477, 479 727, 729 et\u2014and 731 61 63, 53a, 55 60, 62, 64 184, 186 efr\u2014and 188 St-Hubert.St-André.St-André.St-André.Roy est\u2014east.St-André.Cherrier.Mentana.Pare Lafontaine\u2014 Lafontaine Park.Pare Lafontaine\u2014 Lafontaine Park.Anastasie Charbonneau, veuve de\u2014widow of Jacques Antoine St-Jacques.Marie-Louise Cardinal.Marie Délima Forget, épouse de\u2014wife of Daniel Riopel.Jean Louis Charest.Nelly Dowie, épouse de\u2014wife of Napoléon Morrissette.Joseph Tremblay.Napoléon Larivière.Alexandra Bouchard, veuve de\u2014widow of Jean Louis Philippe Houde.Cléophas St-Aubin.17.95 124.55 218.60 332.85 187.97 418.01 165.93 250.37 287.47 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations an miellés\u2014 Annual assessments.Cotisations an n uel les\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Lafontaine.lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.Lafontaine.00 AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continue a.Node la cédule Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of ward for municipals purposes Ste-Marie\u2014 St.Mary's Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.s § aw a* 1 >2 a|l life It* 22 Partie de\u2014part of 21 Partie de\u2014part of 71 123 146 166 166 166 166 166 166 166 166 166 866, 868,868a, 870, 872,874 et-and 876| 817, 819, 821, 823 et\u2014and 825 271, 272,273 275, 276 284, 285 291 296 307 308 309-1 341 385 76, 78, 80 49, 51 53, 368, 368a, 370, 370a, 372 374, 376.378, 380, 382, 384, 386, 388a et-and 390a 395.397 517, 519 et\u2014and 521 533, 535, 537, 539 661,563 581, 583 490, 492, 494, 496 627,629 631, 633, 635.637, 639 500, 502 612,614 545, 547 .Foreyth.Notre-Dame Est-East.Notre-Dame Est\u2014East.Panet.Plessis.Forsyth.Frontenac.Fronteanc.Frontenac.Havre\u2014Harbor.Frontenac.Frontenac.Havre\u2014Harbor.Frontenac.Iberville.Joseph St-Jean.Henri Brouillet.Joseph-Ulric Meunier.Lea Desjardins, épouse de\u2014 wife of\u2014J.-Bte Adolple alias Dolphée Wilson.Joseph Tremblay.Oscar Boyer et\u2014and Israel Nantel.Arthur Hi n t on.Marie Louise Brien, épouse de \u2014wife of Rémi Brault.Edmond Martel.Edmond Martel.Edmond Martel.Adolphe Noel, père.Alice Monette, épouse de wife of Josephat Guertin.333.20C otisations annuelles-Annual assessments.316.15 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.269.88 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.189.02 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.32.56 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.371.71 Cotisations spécial Special assessments.55.05 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.173.09 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Spécial and annual assessments.178.82 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.149.16 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.279.28 Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments.58.37 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-JaMarie-St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary'a Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary'a Ste-Marie\u2014 St.Mary's.70.56 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.166 'S a es \"3 \"53 «cE.^.J o >, =b\"»u eg O > ?OS P CS < C 5 Se- 9 Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 fit.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.166 166 166 171 173 173 173 193 195 229, 230 248 253 Partie de\u2014part of 255 283 369 ,375 408 439 594, 595 596 20 262 Partie de\u2014part of 261 313 388, 390 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438 1362c, 1362d, 1362« 224, 224a, 226, 228 et\u2014and 228a 3, 4 Amity.14, 16, 18, 20 12.904, 906.908, 910, 912, 914, 916 58, 60, 62 816 130, 132, 134, 136 158, 160 etr\u2014and 162 131, 133 813, 816 et\u2014and 817 6, 8, 10 45, 47, 49 Frontenac.Logan.Chapleau.Iberville.DeLorimier.Erie.Dorchester est\u2014east.\u2022 Champlain.Dorchester est\u2014east.Maison nc live.Panet.Plessis.Dorchester est\u2014east.Ruelle Sydenham\u2014 Sydenham Lane.Ste-Rose.Israel Nantel.Edmond Martel.Pierre Paul Renaud.Roch Marsolais.Albert E.Vipond et\u2014and Charles W.Vipond.Suzanne O'Neil.Henri Favreau.Joseph St-Jean.John W.Riordan.Margaret Riordan, veuve de\u2014widow of Francis Landorman, Edward Riordan, Michael Riordan, Denis Riordan.Charles Bérard.Roch Roy.Napoléon Mathieu, sr.Philomène Canale, épouse de-' wife of Ephrem Hurtubise.Charles Bérard.Cléophas St-Aubin.15.33 305.58 149.49 204.73 16.74 275.80 69.74 586.89 212.95 217.77 319.11 231.55 125.87 232.55 122.57 Cotisations spéciales.Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations aspéciles.\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles.Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Ste-Marie-St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie-St, Mary's.Ste-Marie-St.Mary's.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Node la cédule Schedule No.Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street 1281 1283 1284 1285 1286 1295 1298 1300 1310 1314 1319 1320 Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.430 Partie de\u2014part of 435 Partie de\u2014part of 440 443 443 443 443 444 444 494 503 504 Partie de\u2014part of 556 584, 585, parties de\u2014Parts of 583 et\u2014and 586 615 636 615 5-1 5-2 4-1 4-2 Partie de\u2014part 4 Partie de\u2014Part of 3 21,22 12,13 9.10 7 11 108, 110 et\u2014and 112 952.954.956.958.960.962, 964, 966, 968 81, 83 951 201, 201a 203, 205 207.207a 209.2111 982, 984, 986, 988 292, 294 118, 118a 23.25 4, 6, 8 et\u2014and 10 334, 336 et\u2014and 338 558, 560, 562, 564.566, 568, 570, 572 et\u2014and 574 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982 984 Papineau.Ste-Catherine est\u2014east.Papineau.Dorchester est\u2014east.Cartier.Ste-Catherine est\u2014east.Cartier.DeLorimier.Burnett.Couture.Dorion.Dorion.\".Demontigny Est-East.Demontigny Est-East.Propriétaire cotisé Assessed proprietor Succession \u2014 Estate Sarah Moody veuve de\u2014widow of Thos.Hinton.Tréfilé Charpentier, usufruitier\u2014usufructuary.Catherine Reid, veuve de\u2014 widow of Bernard Rafferty.Trefflé Charpentier.Trefflé Charpentier, jr., usufruitier\u2014usufructuary.Israel Levinson.H.Chagnon et Cie, Limitée\u2014 Limited, Horace Chagnon, président.Pierre Paul Renaud.Hosanna Re]air.Maxime Jos.L'Ecuyer.Trefflé Charpentier, Jr.Trefflé Charpentier, Jr.Montant Amount claimed Nature des léclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes 202.13 1,402.47 195.32 332.05 974.88 16.42 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.508.16 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.205.02 196.02 302.74 511.77 239.07 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments, 1328 1337 1338 1339 1340 1341 1353 1362 1363 1367 1371 1374 1384 1389 1390 1392 Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014¦ St.Mary's.Ste-Marie-St.Mary's.Ste-Marie-St.Mary's.Ste-Marie-St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.615 636 636 636 636 636 648 733 Partie de\u2014part of 771 785 819 829 Partie de\u2014part of 977 1027 1028 Partie de\u2014part of 1029 1046 1047 23a, 24a, 25a 5, 6 9 10 11 12, 13 14, 15, 16 450 960, 962, 964, 966 963, 965, 967, 969 959, 961 955, 957 157, 159, 161, 163 951,953 221,225 et\u2014and 227 901, 903, 905, 905a et-and 907 338, 340, 342, 344 741, 743, 745, 747 375a, 377, 379 et\u2014and 381 826, 828, 830, 832 360, 362, 364, 366 861, 863, 865, 867, 869 564, 566 et\u2014and 568 393, 395 et\u2014and 397 801, 803, 805, 807, 809, 811 et\u2014and 813 et\u2014and 387 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864 et\u2014and 866 Champlain.Ste-Catherine Eat\u2014East.Panet.Cartier.Demontigny Est\u2014East.Demontigny Est\u2014East.Demontigny Est\u2014East.Demontigny Est\u2014East.Papineau.Demontigny Est\u2014East.Demontigny est\u2014east.Panet.Logan.Maisonneuve.Demontigny est\u2014east.Panet.Plessis.Lafontaine.Plessis.Ontario est\u2014east.Revd.Vladimir Sakovitch.Trefflé Charpentier.Trefflé Charpentier, fils.Philomène Provost, veuve de-widow of Trefflé Charpentier, Sr.Trefflé Charpentier, fils-jr.-usufruitier-usufructuary.Trefflé Charpentier fils-jr.-usufruitier-usufructuary.Théodule David.Ida Dominique, veuve de\u2014 Widow of George Arthur Bernard.Jules Archambault.Jules Archambault.Edmond D.Porcheron.Pierre Paul Renaud.Jules Archambault.Léon Pierre Paul Renaud.Léon Pierre Paul Renaud.The City Realty Investing Company of Montreal Limitée\u2014Limited.107.21 153 62 201.99 138.45 138.45 660.25 1,365.11 222.48 411.63 173.55 414.12.231.71 226.96 173.46 580.78 1,083.60 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles \u2014 Annual assessments.Cotisations anuuelles-Aunual assessments.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.00 AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued No de la cédule Schedule No.\tQuartier Ward\tNo du cadastre Cadastral No.\tSubdivision\tNo de la rue Street number\tRue Street\tPropriétaire cotisé Assessed proprietor\tMontant Amount claimed\t\tNature des réclamations Nature of claims\tNoms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes 1393\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\t1048\t\t868, 870, 872, 874 et\u2014and 876\t\tThe City Realty Investing\t608\t25[Cotisations annuelles\u2014\t\tPapineau.\t\t\t\t\t\tCompany of Montreal Li-mi tée-Limi ted.\t\t\tAnnual assessments.\t 1394\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\t1053 1054\t\t493, 493a, 493fe, 493c, 493d, 495, 497, 499.501, 503\t\tJoseph Aubin dit St-Louis.\t401\t67\tCotisations annuelles\u2014\tPapineau.\t\t\t\t\t\t\t\t\tAnnual assessments.\t 1396\tSte-Marie\u2014 St Mary's.\t1078 1079 1093\t\t878, 880, 882.884 et\u2014and\t\tThe City Realty Investing\t1,482\t47\tCotisations annuelles\u2014\tPapineau.\t\t\t\t886 540, 544, 546, 548 471, 475 et\u2014and 475a\t\tCompany of Montreal Limitée-Limited.\t\t\tAnnual assessments.\t 1397\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\t\t\t\t\tOvila Provost, Amanda Pré-\t182\t24\tCotisations annuelles\u2014\tPapineau.\t\t\t\t\t\tvost, épouse de\u2014wife of Ernest Pelletier.\t\t\tAnnual assessments.\t 1400\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\t1098\t1, 2, 3, 4\t918, 920, 922, 924, 926, 928 et\u2014and 930\t\tThe City Realty Investing Company of Montreal Li-mitée-Limited.\t762\t71\tCotisations annuelles\u2014\tPapineau.\t\t\t\t\t\t\t\t\tAnnual assessments.\t 1406\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\t1101\t18\t645, 647 et\u2014and 649\t\tJean Evariste Desormiers.\t149\t13\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.\tPapineau.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 1414\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\t1101\t124\t504, 506, 508, 510\t\tTrefflé Charpentier, usufruitier\u2014usufructuary.\t152\t45\tCotisations annuelles\u2014\tPapineau.\t\t\t\t\t\t\t\t\tAnnual assessments.\t 1415\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\t1101\t138\t705, 707 et\u2014and 709\tPanet.\u2022.\tOlive Major, veuve de\u2014 widow of P.Amédée Noel, usufruitière\u2014usufructuary.\t140\t53\tCotisations annuelles\u2014\tPapineau.\t\t\t\t\t\t\t\t\tAnnual assessments.\t 1421\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\t1136\t157\t760, 762 et\u2014and 764 777\tSherbrooke est\u2014east.\t\t706\t10\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.\tPapineau.\t\t\t\t\tPanet.\t\t\t\t\t 1422\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\t1136\t161\t784, 786 et\u2014and 786a\tSherbrooke est\u2014east.\tJoseph Robitaille.\t310\t10\tCotisations annuelles\u2014\tPapineau.\t\t\t\t\t\t\t\t\tAnnual assessments.\t 1425\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\tPartie de\u2014part of 1143\t\t\t\tRichard Charles Barry.\t344\t33\tCotisations annuelles\u2014\tPapineau.\t\t\t\t\t\t\t\t\tAnnual assessments.\t 1432\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\t1161\t\t780, 782, 784, 786\t\tPierre Albert Fortier.\t354\t01\tCotisations annuelles\u2014\tPapineau.\t\t\t\t\t\t\t\t\tAnnual assessments.\t 1433\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\t1163\t\t796, 798, 800, 802\t\tMarie Catherine Cordelia Du-\t361\t40\tCotisations annuelles\u2014\tPapineau.\t\t\t1\t\t\tgas, veuve de\u2014widow of Hon.Georges Duhamel.\t\t\tAnnual assessments.\t 1442 [Ste-Marie-St.Mary's.1445 Ste-Marie\u2014 St.Mary's.1454 1456 1462 1463 1464 Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.1465 ISte-Marie\u2014 iSt.Mary.s.1466 1467 1468 1471 Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 ISt.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.1478 Ste-Marie\u2014 S Mary's.1479 Ste-Marie\u2014 St.Mary's.1480 |Ste-Marie\u2014 jSt.Mary's.1486 jSte-Marie-'St.Mary's.1207 1219 Partie de\u2014part of 1218 1223 1224 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1226 1236 1242 1292 1292 \t791.791a.793, 795.795a.797.799, 799a et\u2014and 801\t \t\t 20\t352, 354 et\u2014and 356\t 52 Partie de\u2014part of 51\t807, 809, 811, 813, 815, 817\t 71\t927,929 et\u2014and 931\t 88\t884, 886 et\u2014and 888\t 89\t890, 892 et\u2014and 894\t 90\t896, 898 et\u2014and 900\t 91\t902, 904 et\u2014and 906\tDorion.100\t\tSherbrooke-Est\u2014East.101\t\tSherbrooke-Est-East.113\t867, 869 et-and 871\t 107\t1094,1096 et\u2014and 1098\tBordeaux.\t733, 735, 737, 739, 741, 743\t 2\t\t 1 Partie de\u2014Part of 2\t1105, 1107, 1109, lllljAmity.\t * Albéric Charest et\u2014and Alice, Desjardins, son épouse\u2014 his wife.The Federal Lumber Company Limitée.\u2014Limited.Zotique Bessette.Joseph D.Lafranee.George Auguste Belisle.Emma Mathilda DagenaiB, épouse de\u2014wife of Wilfrid Lajeunessc.Emma Mathilda Dagenais, épouse de\u2014wife of Wilfrid Lajeunesse.Emma Mathilda Dagenais, épouse de\u2014wife à ^lifriri Lajeunesse.Emma Mathilda Dagenais, épouse de\u2014wife of Wilfrid Lajeunesse.Albert Piché et\u2014and Joseph Ulric Meunier.Albert Piché et-and Joseph Ulric Meunier.Aimé Handfield.346.70: Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.J.-Alcide Molleur.Ella Albert, épouse de of Louis Lehrer.-wife Napoléon Deslauriers.Félix Danseroau.200.42 211.79 210.85 7.50 153.72 153.72 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles.Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.153 72|Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.153.73 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.202.36 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.100.52 Cotisations annueiles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.150.77 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.163.70 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.391.97 Cotisations annuelles\u2014 jAnnual assessments.26.061Cotisations annuelles\u2014 'Annual assessments.557.55 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Jr* 00 -a Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Papineau.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.i AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Node la eédule Schedule No.\tQuartier Ward\tNo du cadastre Cadastral No.\tSubdivision\tNo de la rue Street number\tRue Street\tPropriétaire cotisé Assessed proprietor\tMontant Amount claimed\tNature des réclamations Nature of claims\tNoms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes 1488\tSte-Marie\u2014\t1292\ti Partie de\u2014Part\t565, 567\t\tMarie-Louise Millette, épouse de\u2014wife of Pierre L.W.Dupré.\t135.73\tCotisations annuelles\u2014\tSte-Marie\u2014 St.Mary'a \tSt.Mary's.\t\tof 11\t\t\t\t\tAnnual assessments.\t 1491\tSte-Marie\u2014\t1292\t36, 37, 38\t548, 550, 652, 554, 556, 558.\tDes Erables.\t\t566.00\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.\tSte-Marie\u2014 St Mary'a \tSt.Mary's.\t\t\t560, 562, 564, 566 et-and 568\t\t\t\t\t 1492\tSte-Marie\u2014\t1292\t39, 40, 41\t524, 526, 628, 530, 532, 534,\tDes Erables.\t\t538.25\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\tSt.Mary's.\t\t\t536, 538, 540, 542, 544, et \u2014and 546\t\t\t\t\t 1495\tSte-Marie\u2014\t1292\t72\t\tDes Erables.\tAdélard Bélanger.\t25.31\tCotisations annuelles\u2014 \\ Annual assessments.\ti-* Ste-Marie\u2014 25 St.Mary'a 00 \tSt.Mary's.\t\t\t\t\t\t\t\t 1496\tSte-Marie\u2014\t1292\t73\t689, 689a\tDes Erables.\t\t25.31\tCotisations annuelles\u2014\tSte-Marie\u2014 St.Mary'a \tSt.Mary's.\t\t\t\t\t\t\tAnnual assessments.\t 1497\tSte-Marie\u2014\t1292\t74\t689, 689a\tDes Erables.\tAdélard Bélanger.\t74.21\tCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\tSt.Mary's.\t\t\t\t\t\t\t\t 1604\tSte-Marie\u2014\t1303, partie de\u2014 de-part of 1302a\t\t\tParthenais\tHon.William Owens et\u2014and James E.Wilder.\t552.84\tCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\tSte-Marie\u2014 St.Mary's.\tSt.Mary's.\t\t\t\t\t\t\t\t 1505\tSte-Marie\u2014\t1305, 1305a, par-\t\t\t\tHon.William Owens et\u2014and\t2,002.02\tCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\tSte-Marie\u2014 St.Mary'a \tSt.Mary's.\tties de\u2014parts of 1304a 1304\t\t\t\tJames E.Wilder.\t\t\t 1608\tSte-Marie\u2014\t1317\t\t36, 38, 40 et-and 42\tHarmonie\tHon.William Owens et\u2014and James E.Wilder.\t210.99\tCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\tSte-Marie\u2014 St.Mary'a \tSt.Mary's.\t\t\t\t\t\t\t\t 1509\tSte-Marie\u2014\t1318\t\t214, 216, 218, 220, 222, 224,\t\tHon.William Owens et\u2014and\t212.56\tCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\tSte-Marie\u2014 St.Mary'a.\tSt.Mary's.\t\t\t\t\tJames E.Wilder.\t\t\t Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Partie du village d'Hochela ga \u2014 Part of the village of Hochelaga.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 8t.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Partie du village d'Hochelaga, maintenant annexé à la Cité de Montréal.\u2014 Part of Hochelaga village now annexed to the city of Montreal.Partie de\u2014part of of 1319 1330, partie de\u2014 part of 1332a 1358 1358 173 1359 Parties de-parts of 1436 et\u2014and 1437 Partie de\u2014part of 1550 Partie de\u2014part of 1573 Partie de\u2014part of 1594 22 22 22 117 Partie de\u2014Part of 136 Partie de\u2014Part of 191 23 37 213, 215 et\u2014and 217 706, 708 773, 775, 777, 779 et\u2014and 781 128, 130, 132, 134 347, 349 et-and 351 190 39 et\u2014and 41 79, 79a, 796, 81, 81a, 816, 83a, 836 1102, 1104 72 et\u2014and 73 262 344 173 402, 404, 406, 408 et\u2014and 412 Larivière Fullum Fullum Sheppard Dufresne Dufresne Fullum Parthenais Ontario est DoBeaujeu Valois.550, 552, 554, 556 et\u2014and 558 536, 538, 540, 542 et\u2014and 544 Valois.Chambly I Benjamin La vallée.Hon.William Owens et-James E.Wilder.-and Amédée Bouchard et\u2014and Merille Guertin \"Guertin «t Bouchard.\" 31.52 700 S5 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.209.30 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.François-Xavier Lenoir.210.53 Yvonne Bouchard, Hormisdas Dubuc.Hormisdas Ménard.Olive Sa variât, veuve de\u2014 widow of Auguste Carrière.Charles Desjardins.Rouer Roy A Cie.Joseph Lecavalier.Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre Joseph Champagne,.François Xavier St-Onge, Dlle Régina Létourneau, John Patrick Kelly, Joseph An-thime Couture, et\u2014and Anthime Fortin.Charles Oucllctte.18.12 104.63 151.51 16.40 404.S2 89.72 150.73 127.64 138.77 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spécial Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Obtisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie-St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie-St.Mary'a Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary'a Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Node I la cédule Schedule .No.Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street 1637 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1647 1648 1640 1651 Sa ¦o .s* p a §2 S a~o S 8 si e o I?5 « » > te ce \u2022o S .2 W 23 23 23 23 23 23' 23 23 23 23 23 23 339 Partie de\u2014Part of 449 et-and 450 454 455 461 467 468 472 473 474 et-and 4 501 170.170a et\u2014and 1706 188.190, 192 et\u2014and 192a 194, 196, 196a et\u2014and 198 180, 182 efc\u2014and 184 132, 134 et\u2014and 136 126, 128 et\u2014and 130 Stadaoona Joliette.Nicolet.Nicolet.Nicolet.Stadacona.Stadacona.185, 187 et-and 189 235 179, 181, 183 Stadacona.Chambly.Chambly.169, 171, 173.175 et\u2014andlStadacona.177 288.290 et\u2014and 292 Nicolet.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Omer Auclair.Georjrianna Connolly, épouse de\u2014wife of Irénée A.Amiot.Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne \"Pierre J.Champagne & Compagnie\".Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne.Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne.Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne.Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne.Antonio Leblanc.Antonio Leblanc.Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne \"Pierre J.Champagne et Compagnie.Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne \"P.J.Champagne & Compagnie\".7.74 152.72 128.26 125.03 129.81 163.31 163.31 169.47 119.52 676.57 132.53 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales.Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spécial Annual and spécial assessments Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga. i se 8 à a o R e, o \u2022s a 23 23 23 23 23 23 23 23 Partie de\u2014part of 28 29 29 29 29 29 29 30 503\t296, 298 et\u2014and 300 504\t302, 304 et-and 306 508\t70, 70a, 706 et\u2014and 70c 581-1\t433, 435 et\u2014and 437 580-2\t 672\t 673\t 734\t \t 263\t124, 126, 128 et-and 130 267\t144, 146, 148 et-and 150 453\t465, 467, 469 et-and 471 830\t 992\t401, 403 et\u2014and 403a 1086\t531,533 et\u2014and 535 131\t \t Nicolet.Nicolet.DeBeaujeu.Chambly.Chambly.Chambly.Chambly.Notre-Dame Est-Ei DeBeaujeu.DeBeaujeu.Davidson.Hochelaga.Aylwin.Aylwin.Darling.Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne \"P.J.Champagne & Compagnie.\" Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne, \"P.J.Champagne & «nie.\" Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne, \"P.J.Champagne & Compagnie.\" Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne.Mary Ellen Guerin.Mary Ellen Guerin.Mary Ellen Guerin.Les Commissaires du Havre de Montréal\u2014Harbor Commissioners of Montreal.Léon Moineau.Antoine Dufresne.Marie LouiscTrcmblay.épousc de\u2014wife of Joseph Paradis.Patrick Dunn.Ernest Audet dit Lapointe et and Mathilda Goulet, épouse de-wife of Louis Racicot.Annie Kenny.épouse de\u2014wife of Patrick Dunn.J.-Faustin Richard.145.31 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.165.50 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.135.64 Cotisations annuelles et spécial» Annual and special assessments.133.51 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.17.29 Cotisations spéciales.Special assessments.37.67 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.17.29 Conditions spéciales\u2014 Special assessments.403 06 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.17.75 Cotisations s péri aies\u2014 Special assessments.117.87 Cotisations annuelles\u2014 Animal assessments.121.41 Cotisât ions annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.48.51 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.17.08|Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.87.71 30.29 Cotisations annuelles-Annual assessments.Cotisations annuelles Annual assessments.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga Hochelaga Hochelaga Hochelaga.00 00 AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued No de la cédule Schedule No.Quartier No du cadastre Ward Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes 1806 1807 1808 1809 1811 1812 1814 1825 1885 1886 1887 1888 ¦ 1 § S -§-3 ¦g 2 Og o I CO \u2022II II OS > II J2 ® 31 31 32 32 32 29 191 192 3 4, 5a 55 10 175 et-and 188 Partie de\u2014part of 33 39 49 49 50 52 52 52 52 21.23,25 et\u2014and 25a 5.7.9 11.13.15.17 et-and 19 Partie de\u2014part of 37 38 317 100 101 102 103 1796 1721.1723 et\u2014and 1725 11 et\u2014and 13 1707 et\u2014and 1709 928 Notre-Dame Est\u2014East.Notre-Dame Est\u2014East.Cuvillier.Cuvillier.Notre-Dame Est-East.Notre-Dame est\u2014east.Dezery.Ste-Catherine est\u2014east.St-Germain.Dezery.Dezery.Dezery.Dezery.Charles Austin Barnard.Charles Austin Barnard.Adélard Foisy, Fortunat Foi-sy et\u2014and Thérèse Guérin, veuve de\u2014widow of Joseph Edouard Foisy.Adélard Foisy, Fortunat Foisy et\u2014and Thérèse Guérin.veuve de\u2014widow of Joseph Edouard Foisy.Les Commissaires du Havre de Montréal\u2014Harbor Commissioners of Montreal.Zénophile Pclodeau.Charles Bérard.J.Albert Jacob et\u2014and Victor Raoul Jacob.Joseph Thauvette et\u2014and Alma Legault.loseph Thauvette et\u2014and Alma Legault.Joseph Thauvette et\u2014and Alma Legault.Joseph Thauvette et\u2014and Alma Legault.51.55 53.68 100.35 196.54 3.246.43 226.91 162.68 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisation\" annuelles Annual assessments.Cotisations annuelles)\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.51.55 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.38.30 36.85 36.85 36.85 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments- Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga. 52 52 52 52 53 54 69 Partie de\u2014part of 70 Partie de\u2014part of 70 Partie de\u2014part of 70 Partie de\u2014part of 71 Partie de\u2014part of 72 Partie de\u2014part of 76 76 Partie de\u2014part of 74 104 105 106 107 et\u2014and 108 97 Parties de \u2014 parts of 55, 56, 57 et-and 58 312 1700, 1702, 1704 et\u2014and 1706 Dezery.Dezery.Dezery.Dezery.Dezery.Dezery.Notre-Dame est\u2014east.1692.1694 1690 et\u2014and 1608 Joséphine Lepage, épouse de-wtfè of Cléophas Dignard.Notre-Dame est\u2014east.Notre-Dame est\u2014east.Notre-Dame est\u2014cast.Notre-Dame est\u2014onst.Partio de , part of 3 1053, 1655, 1657 et\u2014and 1659 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 et-and 17 Notre-Dan.e est\u2014east.Notre-Dame est\u2014cast.Joseph Thauvette et\u2014and Aima Legault.Joseph Thauvette et\u2014-and Alma Legault.Joseph Thauvette et\u2014and Aima Legault.Joseph Thauvette et\u2014and Aima Legault.Mastaï A.Gaumont.Les Commissaires du Havre de Montréal\u2014Hailwr Commissioners of Montreal.Les Commissaires du Havre de Montréal\u2014Harbor Commissioners of Montreal.Les Commissaires du Havre de Montréal\u2014Harbor Commissioners of Montreal.Los Commissaires du Havre do Montréal\u2014Harlmr Commissioners of Montreal.Lai Commissaires du Havre de Montréal\u2014Harlx»r Commissioners of Montreal.Les Commissaire* du Havre de Montréal\u2014Harbor Commissioners of Montreal.Adélard Foisy.Fortunat Foisy ot \u2014 and Thérèse Guérin, veuve «le\u2014widow of Jos.Edouard Foisy.Ruelle Foisy\u2014Foisy Lane Adélard Foisy.Fortunat Foisy et\u2014 and Thérèse Gué rin, veuve do\u2014widow of Jos.Edouard Foisy.36.85 36.85 33.65 112.67 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles ot spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles ot spéciales\u2014 Annual and sj>ecial assessments.Cotisations annuelles ot spéciales\u2014 Annual and special assessments.30.2S Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.151.47 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.335.10 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.175.90 Cotisations annuelles-A initial assessments.108.89 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.36.T7 Cotisation! annuelles\u2014 Annual assessments.252.53 Cotisation?annuelles\u2014 Annual assessments.367.17 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.196.07 Cotisations annuelles\u2014 annual assessments.16'.92 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IM MOVEABLES\u2014Continued Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wa rds for municipal purposes a o S cuts os s! \u2022««-.« s 03 O C * \u2022\"S a S II \u2022S Si il -Il 76 76 76 76 80 80 80 80 80 Partie de\u2014part of 85 11, 12 et\u2014and 13 43, 44 et\u2014and 45 54, 55, 56, 57, 58.59.60, 61.62, 63 et-and 64 124 67 Partie de\u2014part of 143 159 Partie de\u2014part of 191 Parties de \u2014 parts of 211, 212, 213 et\u2014 and 214 1631.1633.1635.1635a.1637.1639.1639a et-and 1641 459.461.463, 465, 467.469, 471, 473 et\u2014and 475 221 et\u2014and 251 350, 352, 354 471, 473, 475, 477 et\u2014and 477a 600 etr-and 602 Ste-Catherino est\u2014east.Stadacona.Préfontaine.Préfontaino.Moreau.Moreau.Moreau.151, 153, 155.157, 159, 161, 163, 163a, 165, 167, 169 et\u2014and 171 477a, 4776, 479.481, 483, 485 et\u2014and 487 Moreau.Pierre Tétreault.Odilon Dugas.Napoléon Sénécal Aimé Sénécal.et\u2014and Arthur G.Bourdon.Mary Aikin, veuve do \u2014 widow of Thomas Bulger.Narcisse Giroux.Succession \u2014 Estate Arthur! Spraggs.Moreau.Trefflé Charpentier.Stadacona.Notre-Dame est\u2014east.Joseph Hector Nault.Les Commissaires du Havre de Montréal\u2014Harbor Commissioners of Montreal.756.53 239.09 117 17 10.57 178.27 51.45 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.Cot isations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.Cotisations spéciales-Spccial assessments.Cotisations spéciales-Spécial assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.119.43 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.87.17 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.351.50 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments .620.32 Cotisations annue'.les-Annual assessments.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.oc oc 1930 1937 1938 1939 1941 1943 1944 1945 1946 1949 1951 1952 1953 *1954 1975 I.SI M es a a a c - G 5Î 'S § 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 Parties de-parts of 120, 121 et-and 122 123, 124, 125 et \u2014and 126 Partie de\u2014part of 127 Parties de-parts of 826, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 860 1785 1796 1854 1928 1929 1930 1931 1940-2 1943-2 1943-1 1942-2 1942-1 1941-2 Partie de\u2014part of 1949 2201 Ste-Catherine est\u2014east \u2014and Ontario est\u2014east.37, 39, 41 1655, 1657 3 et\u2014and 5 1701.1703 1.3,5 1705, 1705a 1709.1709a ot\u2014and 1713.1715 37, 39, 4! 57, 63, 65 55, 59, 61 45, 5;,53 109, 111, 113 480, 482 1711 Ontario est\u2014east.Hogan.Ontario est\u2014east.Montgomery.Ontario est\u2014t?ast.Wurtele.Ontario est\u2014east.Ontario est\u2014east.Ontario est\u2014oast.Wurtele.Wurtele.Wurtele.Wurtele.Wurtele.Hochelaga.The .luliilee Amusement Company, Limitée\u2014Limited.Frank Eldcn Came.Abraham Mendelsohn.Samuel Marcus Fridman.Léonce April.Sarah Olitsky, épouse de wife of Isaac Brodsky.Sarah Olitsky, épouse de wife of Isaac Brodsky.Sarah Olitsky, épouse^dc\u2014 wife of Isaac Brodsky.Sarah Oljtsky, épouse de wife of Isaac Brodsky.J.O.Dubois.J.O.Dulwis.J.O.Dul>ois____ J.O.Dubois____ J.0.Dubois____ Samuel Farrand.757.82 672.61 69.35 110.71 293.67 399.68 191.78 191.78 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and - \u2022 -monts.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.( 'oii-ations annuelles et sjjéoiales-Annual Bttd special assessments.Cotisations annuelles et spécialcs-Annual and special assessments.< 'otisations annuelles\u2014 Annual assessments.l'otisations annuelles\u2014 Annual assessments.190.19 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.116.22 116.09 124.91 124.96 114.98 76.81 ( St >t is.i | ions annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et sociales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and si>ecial assessments.Ste-Marie\u2014 9t Mary's.Hochelaga.te-Marie\u2014 St.Man's.Ste-Marie\u2014 *t.Mary's.Bta-lfaie ¦ St Mary'-.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.-^to Marie\u2014 St Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.^te-Maric\u2014'-St Mary's.\"«te-Marie\u2014 St Ma: y's.Ste-Marie\u2014 3t Man 's.^te-Marie\u2014 3t Man s.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.ste.Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.00 00 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014«Suite Quartier Ward J2S fi j S te?II No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 2227 2297 2315 2318 2322 2325 et \u2014 and 2326 2472 2583 et \u2014 and 2584 2594 et \u2014 and 2595 3069 3070 3071 3072 177, 179a, 1796, 179c 205, 207 301,301a 230, 232 74,76,78 80,82,84 86,88,90 92,94,96 \t 204,\t206 ____ 424a,\t426a Rue Street Hogan.Montgomery' Wurtele.Wurtele.Wurtele.Hochelaga.Hochelaga.Hogan.Hogan.Brown.Brown.Brown.Brown.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Natuie of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Edmond Martel.Edmond Martel.Cléophas\"^t-Aubin.Cléopha3 St-Aubin.Léonce April.Edmond Martel.Cléophas St-Aubin.Cléophas St-Aubin.Zenon Brien dit Desrochers.Alcide Rivet.Alcide Rivet.Alcide Rivet.Alcide Rivet.146 95 20 18 57 272 34 64 152 125.125.125.124.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.< 'ot isations annuelles\u2014 Annual assessments.i ot is;;tions annuelles\u2014 Annual assessments.' Jotisatioos annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.t \"otisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annua! and special assessments.lotisatione annuelles et spéciales\u2014 Annual and spatial assessments.i 'oti-aiioi,- annuelles et spéciales\u2014 Annual and spatial assessments./Otiaations annuelles et spéciales,\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et s|)éciales\u2014 Annual and special assessments.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary'a Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.;to-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Marys.Ste-Marie\u2014 s;.Mary's.ste-Marie\u2014 M.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 >t.Mary's.ite Math\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments. Partie du village d'Hochelaga, maintenant annexé à la Cité de Montréal.\u2014 Part of Hochelaga village now annexed to the city of Montreal.o s Si 9*5 b a a « E I si (0.2 SS of\"1 i 148 148 159 1 1 1 1 6 7 8 10 10 12 12 12 3073 3074 91a 307 423, 424 425, 426 427 Parties de-parts of 433, 434 53 69 i Parties de-parts of 29,30,31 59, 60 31a 125 Partie de\u2014part 124 98,100,102 104,106,108 343, 345, 347, 349 140, 142 et\u2014and 144 600, 602, 602a, 602b 708, 710 582, 584 etr-and 586 165, 167 9, 11, 13 480, 482, 484 474, 476, 478, 480, 482 510, 512, 514, 516 et\u2014and 520 1191, 1193, 1195, 1195a 410, 412 1214.1216 Brown.Brown.'.Elm.Marquette.Papineau.Papineau.Pare Lafontaine\u2014 Lafontaine Park.Pare Lafontaine\u2014 Lafontaine Park.Brebœuf.Christophe Colomb\u2014 Rachel est\u2014east.Montana.Marie-Anne.St-Hubert.Rachel est\u2014cast.Chateaubriand.\\lcide Rivet.\u2022Vlcidc Rivet.Stephen Vallée.C.Urgol Coupai.Henri Foucreau et \u2014and Aimé Handheld.Henri Foucreau.Cordelia David, épouse de -wife of Alex.Martinbeau.Raphael Fugère.Wilfrid Hamcl.Narcisse Boaudry.Raphael Marks, Barnet D.Adelman, Solomon Adol-man et \u2014 and Benjamin Horwitch.Lucia Ieblane, Maria Leblanc.Antonio Leblanc, Elphcge Leblanc, Maurice Leblanc, Lucien Leblanc.Etienne April et\u2014and Eugène April.Corinne Lepine, épouse de\u2014 wife of F.X.Vézina.124 4'j ( 'otisations annuelles et spéciales\u2014 'Annual and special assessments.124.51 13.3?133.40 234.94 278.11 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.( \"oti< il ions spéciales\u2014 -\"P-m-ial assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and s|>ecial assessments.Cotisât ions annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisai ions annuelles\u2014 Annual assessments.340.2( ( otisat ions annuelles\u2014 [Annual ¦¦awaiwiiU 153.66 230.35 180.36 301.81 461.63 290.88 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annua! assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.13.98iCotisations spéciales-Spécial assessments.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.Ste-Marie\u2014 St.Mary's.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.00 00 ^4 AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipa.purposes \"3 .eg \u2022So 3* il si si p «\u2022= an 3 i 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 Parties de-parts of 11 et\u2014and 12 Partie de\u2014part of 281 Parties de-parts of 429, 430, 431 432 Parties de-parts of 429, 430, 431 432 528,529 530,531 544,546 546 839 874 875 897 898 292, 294 1136,1138 334,336 330,332a 890, 892 et\u2014and 900 285, 287, 289, 291, 293, 295 291,293 330 689d, 689« 689c, 689b 647, 649 et-and 651' Mont Royal est\u2014 Mount Royaljeast Berri.Rachel est-east.Rachel]est-east.St-Denis.Duluth est\u2014«ast.Drolet.Drolet.Henri Julien.Henri Julien.Henri Julien.Simon Levin.Joseph Boucher.François Villeneuve.François Villeneuve.Israel Lemieux.Israel Lemeiux.Israel Lemeiux.Rose Delima Forget, épouse de\u2014wife of Daniel Riopel.Israel Lemeieux.Israel Lemieux.Arthur Lemeiux.225.SI 64.00 179.36 214.32 691.23 320.32 87.20 125.48 65.87 71.74 131.84 Cotisations annuelles et spéciales Annual and special assessments.Cotisations annuelles Annual assessments.Cotisations annuelles Annual assessments.Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuel les\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spécial.Annual and special assessments Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J,-Bte.St-J.-Bte.StrJ.-Bte.StJ.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte. B.OS ca SI \u2022®S §° P f) 16 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 23 41 57 65 134 161 163 158 200 210 899 900 901.902 Partie de\u2014Part of 903 910 911 912 1170 1171 1172 1285 Partie de\u2014Part of 1286 658.655 et-and 667 250,262 646,648 642,644 638,640 620.622 624, 626 628, 630 971,973 1505 1401,1403 90, 92, 94, 96 1291, 1293, 1293a, 1295.1297, 1299 463, 465, 465a, 465b, 465c, 465d, 467, 469 1342, 1344,-1346, 1348 551,553 et-and 555 571, 573, 575, 577 699, 701 et-and 703 30, 32 Hôtel de-Ville.Henri Julien.Duluth est-east.Henri Julien.Henri Julien.Henri Julien.Laval.Cadieux.Cadieux.Rachel est\u2014east.Cadieux.Coloniale.Cadieux.Coloniale.Coloniale.Coloniale.Mont-Royal est.Mount Royal east Arthur /-cm i eux.I 116.95Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Israel Lemeiux.Israel lemieux.Israel Lemieux.Israel Lemieux.Itha Brownstein.veuve de\u2014 widow of Hyman Rosen.Moses Segal.Cléophas St-Aubin.Jacob Finestone.Stephen A.Delorimier.Joseph Caplan.Jacob Caplan, et-and Morris Caplan.Etta Brownstein, veuve de\u2014 widow of Hyman Rosen.Rachel Schwartz, épouse de\u2014 wife of Israel Schafer et\u2014 and Abraham Edinger.Jacob Latt.Joseph Boucher.David Rabow.Philias Archambault.|St-J.-Bte.204.89|Cotisations annuelles et spéciales\u2014 StJ.-Bte.Annual and special assessments.87.89 Cotisations annuel les et spéciales\u2014 St-J.-Bte.Annual and special assessments^ 87.89 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 St-J.-Bte.Annual and special assessments.87.47 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 St-J.-Bte.Annual and special assessments.354.47 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 St-J.-Bte.Annual and special assessments.130.24 Cotisations annuelles\u2014 St-J.-Bte.Annual assessments.40.39 Cotisations annuelles\u2014 StrJ.-Bte.Annual assessments.189.59 Cotisations annuelle* et spéciales\u2014 StJ.-Bte.Annual and special assessments.40.39 Cotisations spéciales\u2014 StJ,-Bte.Special assessments.19.69 Cotisations sépciales.Special assessments.48 Cotisatilns annuelles.\u2014 Annual assessments.13.33 Cotisations spéciales\u2014 StJ.-Bte.Special assessments.163.07 Cotisations annuelles\u2014 StJ.-Bte.Annual assessments.122.02 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 St-J.-Bte.Annual and special assessments.14.23 Cotisations spéciales\u2014 St-J.-Bte.Special assessments.11.71 Cotisations spéciales\u2014 StJ.-Bte.Special assessments. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVABLESE\u2014Continued Node Is\tQuartier\tNo du cadastre\t\tNo de la rue\tRue\tPropriétaire cotisé\tMontant\tNature des réclamations\tNoms des quartiers pour fins cédule\t\t\t\t\t\t\t\t\tmunicipales \t_\t_\tSubdivision\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014 Schedule\t\t\t\t\t\t\tAmount\t\tNames of wards \tWard\tCadastral No.\t\tStreet number\tStreet\tAssessed proprietor\tclaimed\tNature of claims\tfor municipal No.\t\t\t\t\t\t\t\t\tpurposes os ~ a CJ c -2 U ll cS 9 *U |§ '3 o Ij \"7.2 ¦7.a, Sa as =3 > 242 243 260 Partie de\u2014part of 266 Partie de\u2014part of 266 Partie de\u2014part of 302 376 Partie de\u2014part of 378 1449, 1451, 1451a, 1453, 1453a, 14536, 1453c, 1453d et\u2014and 1455 618, 620 600, 602 596, 598 1277 1370, 1372, 1376, 1378 1363, 1305, 1367, 1369 1379.1381, 1383, 1385 et\u2014and 1387 St-Dominique.Coloniale.Coloniale.Coloniale.St-Dominique.St-Dominique.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard.P.J.Champagne & Cie, Marie Hose Labelle, épouse de\u2014wife of Pierre Joseph Champagne.Amablc Frigon, fils\u2014Jr.Valeric Lagrenade.Raoul Lagrenade.Joseph Briard.Lupei Herman.Charles Fabien Vinet.6.42 Cotisations spéciales-Spécial assessments.42.79 65 92 65.92 12.66 859 92 731.72 Cotisations annuelles et sociales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations annuelle \u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 .Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.St-J.-Bte.Sujet à la substitution créée par le testament de Charles Fabien Vinet, devant N.Brodeur, N.P., le 1er février 1890, et dûment enregistré au bureau d'enregistrement poux Hochelaga et Jacques-Cartier, le 18 février 1890, sous le No 32628.\u2014Subject to the substitution created by the last will and testament of Charles Fabien Vinet.before N.Brodeur, N.P., on the 1st February, 1890, and duly registered in the registry office for Hochelaga and Jacques-Cartier, on the 18th February, 1890, under the No.32628.Partie de\u2014part of 380 383 429 434 24 1407, 1409 1411, 1413 1226, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246 1221 38, 40, 42 et\u2014and 44 Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard.Clarke.Duluth Ouest\u2014West.Moses Mergler.Moses Mergler.Boulevards Limitée\u2014Limited Anna Lieger.épouse de-wife of Morris Friedman.333.04 736.24 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.1.9S5.69 426.30 Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessment-*.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-J.-Bte.St-J.-Bte.StJ.-Bte.StJ.-Bte. 2234 2235 2236 2238 2239 2261 2266 2281 2282 2286 2297 2304 2305 2600 M s i ; «\u2022«,2 S 9 .\u202232° 5 HI -\"s « \u202220 Ni JS * o -3.s>o 0< -s « fS S a ïrf ¦1 a j ¦ScQ a3 31 j 1*3 «If 211\tfll\t\t\tUna Blum be ru.veuve de\u2014 Waclow Païusis, John Pazusis, Martin Pasutois, Gos-tancya Pazusis.Justyn Pa-zusjs, Boles tan Pazusis John Pazusis, Malvina Pazusis et\u2014and Adélia Pazusis.\t7.40\tCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\tDelorimier.\t\t\t\u2022\t\t\t\t 211\t79\t\tPapineau\t\t1 11 .13\tCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\tDelorimier.\t\t\t\t\t\t\t 211\t118\t2566\t\tCharles Bernier\t12.73\tCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\tDelorimier.\t\t\t\t\t\t\t 211\t119\t\tCartier.\tCharles Bernier\t8.48\t('fttmîltionn anviiiollna\tDelorimier.\t\t\t\t\t\tAnnual assessments.\t Partie de\u2014part of\t\t\t\tT 1H< OU\t27.32\tCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\tSt-Denia of 64\t\t\t\t\t\t\t 325\t5 et\u2014and 9\t415, 415\tMont-Roya! est\u2014east.\tNormand Laherge.\t8.52\tCotisations spéciales\u2014 Special assessments.\tSt-Denia 325 325\tPartie de\u2014part of 51 et\u2014and 48\t457, 459\tMont-Royal est\u2014east.\tAlice Normand, épouse de\u2014 wife of Gustave C.Delorimier.\t308.38\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.\tSt-Denia St-Denis.325\t255, 256\t1359, 1359a et\u2014and 13596\tSt-André.\tLouis Goldsman et \u2014 and Solomon.\t14.90\tCotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\tSt-Denia \t\t45, 47 et\u2014and 49\t\t\t\t\t 328\t461-2\t252, 254, 256, 258 et-and\t\tLuce Brosseau.\t135.64\t\tSt-Denis.\t\t260\t\t\t\t\t 328\t462-2\t250\t\t\t137.90\tCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\tSt-Denis.\t\t\t\t\t\t\t 328\t486, 487 et-and\t664a\tGilford.\tHome Chocolate Creamery Limitée\u2014Limited.\t55.10\tCotisations spéciales\u2014 Special assessments.\tSt-Denis.\t488\t\t\t\t\t\t 328\tPartie de\u2014Part\t197, 199, 201\t\tCharles Henri Catelli\t427.25\tCotisations annuelles\u2014\tSt-Denis.\tof 602 i\t591,593\tMont-Royal Est-East.\t\t\tAnnual assessments.\t 329\t21\t242 et\u2014and 244\t\tJoseph Ortiz.\t85.89\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.\tSt-Denis.\t\t\t\t\t\t\t 330\tParties de-Parts of 84 et-and 85\t689, 691\tMont-Royal-Est\u2014East.\t\t11.51\tCotisations spéciales\u2014 Special assessments.\tSt-Denis.331 1\tPartie de\u2014Part of 94 ¦\t574 et-and 574a\t\tJoseph Milord et-and Jean-Bte Milord.\t97.41 i\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and Special assessments.\tSt-Denis.\t\ti\t\t\t\t\t AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Quartier Ward \u2022o o \u2014\" e il S H a 2 \u2022afl.S.2 S GO m s* d ° \u2014 (o « M -0_eS -1 11 No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue : treet 331 Partie de\u2014Part of 100 331 Partie de\u2014Part 3P of 122 331 Partie de\u2014Part 6 of 193 331 Partie de\u2014Part of 228 339 39 et-and 40 363, 339 353 339 651 et-and 652908, 339 Partie de\u2014Part of 660 et-and 339 661 339 762-1 339 763 339 785-1 339 1 784-2 534 et-and 536 8, 398a, 3986, 398c 398d et-and 398c 28.628a et-and 6286 563 365.367.369.371, 373 et\u2014and 375 235 et\u2014and 237 910, 912, 914.916 et-and 918 864 et-and 864a 473.473a 475 et-and 475a 1280, 1282 1284 et-and 1286 Chambord.Chambord.Delanaudière DeLanaudière DeLanaudière Fabre.Papineau.Papineau.Fabre.Papineau.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Henri Brouillet.Charles Bernier.Alexandre La vigne.Napoléon Ferland.Alice Brosseau.épouse d( wife of Joseph Avila Mol-leur et\u2014and Luce Brosseau Emma Laverdure, épouse de-wife of Gustave Auguste Dumont.Joseph Achille Lacombe.Joseph Raphael Beauchamp.J.-Adolphe Daigneault.Adélard Martin.72.82 173 33 72.82 52.68 399.00 91.96 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations anunelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.St-Denis.St-Denis.St-Denis.St-Denis.St-Denis.St-Denis.437.09.Cot isations annuelles et spécial Annual and special assessments 460.50 Cotisations annuelles\u2014 (Annual assessments.21.40,Cotisations spéciales-Spécial assessments.St-Denis.St-Denis.St-Denis.241.55 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 :St-Denis.Annual and special assessments. 2922 S\"5 .2* es TJ 0) ~ M a *> 3 a a fl .5 * 3 S m *| OS «Si \u2022g es QQ«m I 488 488 488 488 488 488 488 488 488 489 489 489 256 386 88a et\u2014and 89a 157a 356 et\u2014and 357 420 et partie de-and part of 421 1259 1260 1261 153 299 300 2805, 2805a et\u2014and 2807 2194, 2196, 2198, 2198a et\u2014and 21986 2390 3478, 3480, 3482, 3484, 3486 et\u2014and 3488 2347 et\u2014and 2349 2013 et\u2014and 2015 3129, 3131, 3133 3317 et\u2014and 3319 St-André.St-André.Boyer.Boyer.Christophe Colomb\u2014 Boyer.DeLanaudière.DeLanaudière.DeLanaudière.St-Hubert.St-Hubert.St-Hubert.Annande Martin, épouse de\u2014 wife of Joseph Georges Gi guère.J.Edmond Tremblay.Henri Chartrand.Eusèbe Foisy, \" Fils \".Albert Laurier.Stephen Vallée.Jean-Bte Richard.Jean-Bte Richard.Jean-Bte Richard.Louis Philippe Alexis Girard.Peter McNamee.Peter McNamee.13.88 31.17 57.31 91.74 44.96 31.76 8.89 8.89 29.19 25.32 35.00 35.00 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéeiales-Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.St-Denis.Abu nt sic-Bordeaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Abu nt sic-Bordeaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor- g deaux.§ Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux. AVIS DE VENTE DT M MEUBLES\u2014Suit» NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Node la cédule Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street lîsb IIPI §9 a o* ?a\u2014\"o c o o o aSS-a-¦§ S \u2022SaS « 5 ££¦3:5 §S m So, 3 S* li^ Il 2 9 o 2 « \u2022 e o \u2022a-a a I « I .p,\u2014 o _J «fi] .2 o\"C< § o» p.o fi 2630 2643 1271, 1272, partie de\u2014part of 1270 de\u2014Part of 1444 1449 1450 1566 Partie de\u2014Part of of 1665 1674 1674 1703 108.109\t2703 et\u2014and 2705 2545, 2546, 2547\t1150 2548, 2549,\t 2550, 2551\t \t104, 106, 108, 110, 112, 114, \t116, 118, 120, 122, 124.126 \t1010 1\t Partie de\u2014Part\t of 1\t \t18, 18a, 20, 22, 24 \t2328, 2330 70\t22, 24 et-and 26 71\t16, 18, 20 134\t2591.2593 Chateaubriand.Crémazie.Agnès.St-Antoine.Richelieu.Richelieu.Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Natuie des réclamations Nature of cl aims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Langevin.St-Jacques\u2014St.James.Caselais.Caselais.Notre-Dame Ouest-West Oscar La treille.Samuel Carsley, John G.Carsley, \" S.Carsley Com-Company \".Alice Winifred Robbins.Melville William Holdsworth, George Percy Holdsworth \"The Holdsworth Coy\".Ernest Charette.Hector-M.\\Jaher.Emma Pepin dit Barolet, veuve de\u2014widow of F.-X.Leduc.Alphonse Lacroix.Alphonse Lacroix.GeorgiauaDesgroseilliers.21.97 152.26 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spécial Special assessments 901.64 Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments.137.22 Cotisât ions annuell Annual assessments.71.39 261.41 161.35 132.38 132.38 Cotisa tionsannuellesetspéciales\u2014 Annualandspecialasses8ments.Cotisa tionsannuelle.s\u2014 Annual assessments.Cot isat ion s an n uell esc t spéciales\u2014 Annualandspecial assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisa tionsannuelles\u2014 Annual assessments.129.78 Cotisations annuelles\u2014 Annualasscssments.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahunteic-Bordeaux.St-Henri\u2014 § St.Henry.Jo St-HenrL St.Henry.St-Henri\u2014 St.Henry.St-Henri\u2014 St.Henry.St-Henri\u2014 St.Henry.St-H enri\u2014 StTHenry.St-Henri\u2014 St.Henry.St-Henri\u2014 St.Henry. 3129 3135 3162 3176 3177 8196 3197 3198 3199 3202 3204 3206 3208 3217 \"S '§ a h ô So T3 os O.S 53 B a \u2022si S a tS H II o g sa o \u201e ¦a 1704 1705 1705 1972 314,316 35 Partie de\u2014Part of 36 1, 3, 5, 9 159, 161 et\u2014and 163 1792 St-R6mJ.|Alice Winfred, Melville Rob-bins.DeCourcelles.Notre-Dame Ouest-West Léda Pilon.Succession\u2014Estate Geo.C.Nicholson, succession \u2014Estate Mary Jane Rémillard, épouse de\u2014wife of G.C.Nicholson, Robb Geo.Campbell, Ex.Test.,Walter H an ua n, curateur-curator.237.57 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 St-Henri\u2014 Annual and special assessments.St.Henry.241.16 492.46 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuités Annual assessments.St-Henri\u2014 St.Henry.St-Henri\u2014 St.Henry.Sujet a la substitution créée par le testament de Mary Jane Rémillard, épouse de Geo.C.Nicholson et Geo.C.Nicholson, devant W.de M.Marier, N.P., le 25 avril 1901, et dûment enregistré au bureau d'enregistrement pour Hochelaga etlacques-Cartier, le 8 avril 1908, sous les Nos 14913 et 14914.\u2014Subject to the substitution created by the last will and testament of Mary Jane Rémillard, wife of Geo.C.Nicholson and Geo.C.Nicholson before W.de M.Marier, N.P., on the 25th April, 1901, and dulv registered in the remstrv office for Hochelaga and Jacques-Cartier, on the 8th April, 1908, under the Nos.14913 and 14914.' \" 2224 2252 2252a 386 386 386 386 386 569 572 619 629, 631 632, 635 764 833, 834 837 2402 122 156 167-1 159-2 160 83, 85 400, 402 et\u2014and 404 697, 699, 701.703, 705, 707 709, 711.713 555.557, 559 1273, 1275, 1275a, 1277, 1279, 1281 1455, 1459, 1461 489, 491, 493.495.497.499 689, 691, 693.695 124, 126.128.130, 132.132a 134,136,138,140, 142,144 173 Bérard.Atwater.Atwater.St-Antoine.St-Antoine.Notre-Dame ouest\u2014west.Notre-Dame ouest\u2014west.Atwater.Albert.Quesnel.Toussaint Ste-Marie.Napoléon Archambault.Collin M'inro.Cajetan Dufort.Jos.Antoine Hébert____ Cléophas St-Aubin.Cléophas St-Aubin.Harry Robinson.Cléophas St-Aubin.Duvernay.Emélie Lepellé dit Lahaie, veuve de\u2014widow of Ls Jules Gaudry dit Bourbon-nière, Ls-Jules Gaudry dit Bourbonnière, Malvins Gaudry dit Bourbonnière.Wilbrod Quenneville.131.20 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.41.26 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.590.63 Cotisations annuelles\u2014 Annum assessments.228.50 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.67.26 Cotisations annuell Annual assessments.397.79 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.173.33 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.485.63 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.141.42 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.235.54 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.208.88 Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments.St-Henri\u2014 St.Henry.St-Henri\u2014 St.Henry.St-Joseph.St-Joseph.St-Joseph.StJoseph.St-Joseph.St-Joseph.St-Joseph.StJoseph.StJoseph.co AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street I - ¦ - « a \"S5 II y Sic AI s \" iu ** o «s 25 25 25 25 25 25 25 27 149 149 149 149 149 149 Partie de\u2014part of 3 40 82 90 101 612 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 228 201, 203, 205, 207 837a, 839 812 801 < Gatineau.871 Gatineau.Albani.Maréchal.Maréchal.Avenue du Congrès.Lacombe.Queen Mary road.Queen Mary road.Queen Mary road.Queen Mary road.Queen Mary road.Queen Mary road.Queen Mary road.NOTICE OF SALE OF IM MOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales *| Names of wards for municipal purposes Leslie Higginbottom, Samuel Hinginbottom, Oswald Higginbottom, Eva Higginbottom.Henry J.Higginbottom.Tobia Felli.Eugène Bisson.J.-Bte Lalonde.Alexina Laflamme, veuve de-widow of Ls Napoléon Denis.Edouard G oyer.Grégoire Joseph Grégoire Joseph Grégoire Joseph Grégoire ; Joseph Grégoire Joseph Grégoire Joseph Grégoire 1 Joseph Meloche Meloche.Meloche Meloche.Meloche Meloche.Meloche Meloche.Meloche Meloche' Meloche Meloche.Meloche Melocha.et\u2014and ct\u2014and et\u2014and et\u2014and et\u2014and et\u2014and et\u2014and 12.93 Cotisations spéciales\u2014 fN.-D.de Grâces Special assessments.15.86 Cotisations spéciales\u2014 N.-D.de Grâces Special assessments 83 Cotisations spéciales-Spécial assessments 38 Cotisations spéciales-Spécial assessments.58 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 N.-D.de Grâces Annual and special assessments 31 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.431.68 Cotisations annuelles\u2014 N.-D.de Grâces Annual assessments.69.83 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 N.-D.de Grâces Annual and special assessments S3 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 N.-D.de Grâces Annual and special assessments.69.83 Cotisations annuelles etspéciales\u2014 N.-D.de Grâces Annual and special assessments.69.83 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 N.-D.de Grâoee Annual and special assessments.S3 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 N.-D.de Grâces Annual and special assessments.69.83 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 N.-D.de Grâces Annual and special assessments 149 69.83 Cotisations annuelles et spéciales.\u2014 N.-D.de Grâces 'Annual and special assessments. I a *> _\u2022 9 « s o \u2014 o \u2022¦CS o> K Q O _ c * Is e » 55 S3 Is O O 149 150 150 150 150 150 150 150 48 150 48 150 48 150 150 150 151 151 151 152 152 18 16 17 18 19 20 25 26 66 27 65 28 64 114 115 249 60 61 143 26 Partie de\u2014Part of 51 Queen Mary road.Projetée\u2014Projected Projetée\u2014Projected Projetée\u2014 Projected Projetée\u2014Projected Projetée\u2014Projected Projetée\u2014Projected Pro j et ée\u2014Pro j ected Projetée\u2014Projected Projetée\u2014Projected Projetée\u2014Projected Projetée\u2014Projected Bona Vista.Victoria.Victoria.Queen Mary Road Grosvenor.Queen Mary Road Grégoire Meloche et\u2014andl Joseph Meloche.Robert H.Preston.Robert H.Preston.Robert H.Preston.Robert H.Preston.Robert H.Preston.Robert H.Preston.Robert H.Preston.Robert H.Preston.Robert H.Preston.Robert H.Preston.Robert H.Preston.____ Walter Baillie.50.25Cot isations annuelles et spéciak Annual and special assessments.Narcisse Forest, Roch Forest, \"Forest et Frères\".Narcisse Forest, Roch Forest, \"Forest et Frères\".Revd.Ambroise Romuald Hétu.John M.Ferguson.Revd.Ambroise Romuald Hétu.101.06 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.102.65|Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.105.82 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.152.33 Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments.150.73'Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessment.460.88 Cot isations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.88.37jCotisationsannuelles et xpéciales\u2014 Annual and special assessments.82.75 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.69.15 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.102.72 Cotisations annuelles etspéciales\u2014 Annual and special assessments.102.72 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.115.60ICotisations spéciales\u2014 jSpecial assessments.44.68 Cotisations annuelles\u2014 .Annual assessments.44 68 12.89 131.65 51.06 Cotisations annuelles\u2014 Annual a«seasments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.jN.-D.de Grâces Jn.-D.de Grâces 'n.-D.de Giâces N.-D.de Grâces N.-D- de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces § N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Node la cédule Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street 0 «>\"3 152 152 151 156a 156a 156a Partie de\u2014part of 160 169 169 .Partie do\u2014Part of 52 53 142 169 2a 4 5 11 Parties de-parts of 10 et-and 12 14 Partie de\u2014Part of 13 34 28 26 29 30 195 50 1307, 1309 et-and 1311 1866 et-and 1866a 1880 et-and 1882 1828 et-and 1830 Queen Mary Road.Grosvenor.Roslyn.Roslyn.Roslyn.Marathon.Westmount.Westmount.Chapleau.Iberville.Iberville.Iberville.Chapleau.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Revd.Ambroise Romuald Hétu.Revd Ambroise Romuald Hétu.Robert H.Preston.Robert-H.Preston.Robert-H.Preston.James-H.Maher.The Metropolitan Realty Company, Limitée\u2014Limited Albert-Pierre Frigon.Edouard Lafortune, et\u2014and Alexina Lajnrtune, épouse de-wife of Raymond Neveu Henri Foucreault.Henri Foucreault, et\u2014and Aimé Handheld.Henri Foucreault et\u2014and Aimé Handheld.Henri Foucreault.23.43 34.49 81.02 81.02 81.02 866.08 114.13 207.24 65.18 10.03 19.33 Votisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spécial Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciale Special assessments.Cotisations annuell Annual assessments.47.OOjCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.76.23 Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier. 132 et\u2014and 133 176-1 et\u2014and 2 175-1 et\u2014and 2 177-1 177-2 178-1 178-2 179-1 Partie de\u2014part of 33 76-1 et\u2014and 2 77-1, 2 et\u2014and 3 78-1, 2 169 170-1 et\u2014and 2 171-1 171-2 172-1 et\u2014and 2 263 Partie de\u2014part of 2 Partie de\u2014part of 3 107 1234, 1236.1238, 1240, Mossier, et\u2014and 1242 1287.1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1299, 1301, et\u2014and 1303 1317, 1321 et\u2014and 1323 1026, 1028, 1030, 1032 et-and 1034 1166, 1168, 1170 et\u2014and 1172 1204, 1206 1208 et\u2014and 1210 1324 1403 Messier.Messier.Messier.Messier.Messier.Parthenais.Parthenais.Mont-Royal est\u2014eats et \u2014and Parthenais.Parthenais.1405, 1407, 1409, 1411, Parthenais.1413 et\u2014and 1413a 1415, 1417, 1419, 1421.Parthenais.1423 et\u2014and 1425 1430, 1432 et\u2014and 1434 Pe 1189.1191 et\u2014and 1193 Delorimier.1217, 1219.1221 otr-and 1223 1008 1476, 1478.1480 et\u2014and 1482 Célina Deniers, veuve de\u2014 widow of Olier Moquin.Marie Blanche Sénécal, veuve de\u2014widow of Clodomir E.Forest Chs Edouard Lamoureux.I 244.29iCotisations annuelles Annual assessments.Chs Edouard Lamoureux.Chs Edouard Lamoureux.Catherine McCaffery, veuve de\u2014widow of Ralph Mur-dock.Jos Charles Jauvin.Alice Brosseau, épouse de\u2014 wife of J.Avila Molleur et \u2014and Délie Luce Brosseau.Georgiana Sénécal, épouse de\u2014 wife of Joseph Dufour dit La tour.Charles E.Lamoureux.Charles E.Lamoureux.Charles E.Lamoureux.Henri Dupras.Bordeaux.Delorimier.Bordeaux.Corsénie Dupras, épouse de wife of Zoel Martel.Jack.W.Jacobs.Praxède Laperrière.275.90 6.02 6.02 6.02 6.06 12.18 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.122.76 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.712.40 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.8.07 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.12.08 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.12.08 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.119.52 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.193 99 Cotisations annuelles et psécial Annual and special assessments 582.21 Cotisations annuelles Annual assessments.10.88 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street eS o y 5U o_ \u2022a o s » B a os .23 5 > .2 ° \u2022 G S » o h «o£-5 ss.af «2° \u20220:5 >> loG |«| e a« \u2022si5 es iï « ?a c S» o o 152 153 153 153 153 153 153 157 108 149 Partie de\u2014part 1421, of 161 Partie de\u2014part of 161a 1484, 1486 et\u2014and 1488 Bordeaux 1009, 1011 et\u2014and 1013 Mont-Royal 1423, 1425 1425a et\u2014and 1616 Partie de\u2014part of 161c 363 et\u2014and 364 11 et\u2014and 12 156\tPartie de\u2014Part \tof 6 156\tPartie de\u2014Part \tof 25 156\tPartie de\u2014Part \tof 26 156\t7 156\tPartie de\u2014Part \tof 27 156\tPartie de\u2014Part \tof 8 156\tPartie de\u2014Part \tof 9 156\tPartie de\u2014Part \tof 25 156\tPartie de\u2014Part \tof 27 156\t10 156\tPartie de\u2014Part \tof 25 156\tPartie tic\u2014Part \tof 27 Papineau.1435,1437,1439,1441, 1443, Papineau.1445, 1447 et\u2014and 1449 j 1874.1876.1878.1880.Cartier.1882, 1884.1886, 1888 et\u2014and 1890 1507, 1509, 1511 et\u2014and 1513 Papineau.Papineau.Papineau.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal put poses Praxède Lapcrrière.| 10.88 Arthur Simard.7.95 Urgel Coupai.Cordelia David, épouse de wife of Alexandre Martim-beau ct\u2014and Agnes David.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.265.49 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.451.15 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.Edmond Martel.259.58 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Ida HelHTt.épouse de\u2014wife of Georges Albani Forest.Henri Foucreault Aimé Handheld.et\u2014and Henri Foucreault et \u2014 and Aimé Handheld.259.38 Cotisations annuelles\u2014 Annua ^assessments.82.08lCotisations annuelles et spéciales-Annuai and special assessments.80.05 ( oti-ations annuelles\u2014 Annual assessments.(Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier. r 3482 3483 3484 3487 3495 3506 3513 3517 3530 3531 3534 3541 3543 3548 3569 I « fi fi S- \u201e o ¦u£ es Z2 4) cd a a a a 85 eg \u2014 > Si es \u2022 s§ 3-5 35 c'S \u20222> 83 03 il e3*0 il 11 il 5 h a o 156 156 156 156 156 156 156 156 156 159e 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 11 Partie de\u2014Part of 25 Partie de\u2014Part of 27 12 Partie de\u2014Part of 25 Partie de\u2014Part of 28 13 Partie de\u2014Part of 25 Partie de\u2014Part of 28 23, 24 et-and 25 73 174 240 263 345 346 387 428 et-and 429 439-3 470-1 513-3 et\u2014and 4 Papineau Papineau 1637, 1637a, 16376, 1639 et and 1639a 1728, 1730.1732, 1734, 1736.1738* 1745.1747.1749 et\u2014and 1751 2019, 2021, 2023 ct\u2014and 2025 2027.2029.2031 et\u2014and 2033 1978, 1980, 1982.1984 et-and 1986 1545a.1547, 1549, 1551, 1551a, 1553, 1555 et\u2014and 1557 60, 62 et\u2014and 62a 1518, 1520, 1520a, 1522, 1424 et\u2014and 1524a 56, 58 et\u2014and 58a Des Erables Des Erables Delorimier Bordeaux Bordeaux Bordeaux Chabot Masson Chabot Masson Henri Fouereault et \u2014and Aim'' Handfield.Henri Foucreault et \u2014 and Aimé Handfield.Henri Foucreault et \u2014 and Aimé Handfield.PoméLn Désy, épouse de-wife of Jules Petit-Jean.John Keejçan et\u2014and Rose Ann O'Neil, veuve de\u2014 widow of Jonh Dillon.Alice Molleur.Arthur Bsaudoin.Télesphore Pelletier.Wilfrid Larose.Wilfrid Larose.Joseph Au 1min.Meclea Burelle.Arthur Beauvais.Alice Aumont, épouse de wife of Arsène Ethier.Alcide Molleur.80.05 91.17 91.17 314.67 15.93 130.26 147.28 15.93 27.17 27.17 205.29 258.44 9.92 179.29 138.88 Cotisations annuelles \u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annua.' and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 S|>ecia.assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Delorimier.Annual and special assessments.' AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Quartier Ward No du cadastre\t\tNo de la rue \u2014\tSubdivision\t\u2014 Cadastral No.\t\tStreet number i 161\t764\t2180, 2182, 2184, 2186 et-and 2188 161\t1035\t2239, 2241, 2243 et\u2014and 2245 161\t1036\t2247, 2249, 2251 et\u2014and 2253 161\t1037\t2255, 2257, 2259 et^-and 2261 160\t\t 211\tPartie de\u2014part of 160\t2421 247 et partie de\u2014 and part of 248\t\t1350 \t\t 8\tParties de-parts of 36 et-and 37\t1787 10\t79\t11, 13, 15 10\tPartie de\u2014part of 95\t26, 28 10\tPartie de\u2014part of 106\t96 10\tPartie de\u2014part of 107\t \t\t 10\tParties de-parts of 106, 107\t.100 10\t164\t2147, 2149 etr\u2014and 2151 Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprieto; Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes nil ÎHfl o a o ° mît -Si § »! àfefl 2*2.g CO S«P CO M IItIi Mm lia Cartier.Bordeaux.Bordeaux.Bordeaux.Jeffrey Lane.Papineau.Des Erables\u2014 Henri Julien.Casgrain.De Gaspé.De Gaspé.De Gaspé.De Gaspé.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrenco Boulevard.Alphonsine Renaud, épouse de\u2014wife of Henri Mathieu.Alphons.ne Renaud épouse de \u2014wife of Henri Mathieu.Alphonsine Renaud, épouse de\u2014wife of Henri Mathieu.Henri Foucreau.Emile Boulé.Délie Virginie Gibouleau.Aimé Handfield.Mary Connors alias O'Connor veuve de\u2014widow of Michael Hughes.Adolphe Lemieux.Sam A with.Arthur Goyer.Avila Gascon.A vil a Gascon Jacob Sugar.139.80 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.152.69 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.152.69 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.152.69 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.14.90 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.11.51 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.78.24 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.83.25 Cotisations annuelles et spéciales.Annual and special assessments.168.70 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.6.54 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.6.54 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.24.29 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.58.72 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.6.84 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Delorimier.Delorimier.Delorjnier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Delorimier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier. 169, 170 175 181, 182 183 381 766 767 810-4 811-4 812-4 813-4 814-5 846-1 846-2 966 Partie do\u2014Part of 1066 1091 1097 1125-1 1125-2 1124-1 1124-2 1129 1185 2177, 217».2181, 2183, 2185, 2187 2219.2221 et\u2014and 2221a 2255, 2257, 2259.2261.2263, 2265, 2267, 2269 2473 2689, 2691 2685, 2687 2785, 2787 502, 504, 504a, 5046 498, 500, 500a, 5006 647, 649 3130, 3132 et - and 3134 69, 71 914 97 62 64, 64a, 66 68, 68a 70, 72, 72a 44, 46, 48 49, 61 Boulevard St-Lauront\u2014 St.Lawrence Boulevard.Boulevard St-Laurent -St.Lawrence Boulevard.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard.Casgrain.Casgrain.Aima.St-Dominique.Buller.DeGaspé.Buller.Mozart.Mozart.Mozart.William Luxemburg.Médéric Archambault.Moses Vineberg.Abraham Mendelsohn.Jean-B.-Adolphe Wilson.Jean-B.-Adolphe Wilson.Adélard Armand Leduc.Jos-Ulric Meunier.Jo8.-Ulric Meunier.Anthime Jolicœur.Max Doubilet.Max Doubilet, Goldy Singer, épouse de\u2014wife of Ben Li-twin.Isaac Wulfston., Leopold Ovila Sauriol.Boris Tansky., Mayer Cohen.21.90 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.34.60 Cotisations spécial Special assessments.34.60 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.149.14 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.163.62 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.163.47 Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments 9.98 Cotisation* spéciales\u2014 Special assessments.175.25 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.180.75 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.93.30 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.324.53 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.97.93 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Laurier.Laurier, laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.co 199.36 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.37.88 Cotisations annuelles\u2014 Annuai assessments.202.69 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.7.57 Cotisations spéciales\u2014 Special assessmenta « AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suit* Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street 2.3 s 5-2 S 3 1 , 11 38 35*3 81 Si EL ail èa ca » fi* 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1192 1431 1489,1490 1499 1573.1574 1575 1576 1618 partie de\u2014Part of 1617 1624 1626 1627,1628 1676 1727 2146 2147 2148 634, 634a, 6346, 636.636a.6366, 638, 640 et-and 640a 674, 676 1958 1968, 1968a, 1970 1972,1974,1976,1978, 1980 3080, 3082, 3084, 3086, 3088 234, 236, 238, 240, 242, 244 210, 212, 214, 216, 218, 220 202, 204, 206.208 81, 83 735, 737 532, 532a 534, 534a 5346, 536, 536a, 538.538a St-Dominique St-Zotique Aima.Aima.Henri Julien.Henri Julien.Henri Julien St-Dominique Suzanne.Suzanne.Suzanne.St-Zotique.DeGaspé.Casgrain.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continue o.Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of ward for municipals purposes j Ovila Lavoie.jAndré-H.Gcndron.Célina Beauchamp, veuve de-' widow of Jean-Bte Pauzé.Gustave Cardinal.Calixta BacGn dit Bast i en .Calixte Bacon dit Bastien.j Calixte Bacon dit Bastien.Alexis P.Bel air.Joseph Ulric Meunier.Joseph Ulric Meunier.Joseph Ulric Meunier.Oliva Samson.Joseph Maloney.Albert Brière.22.60jCotisations spéciales\u2014 Special assessments.53.43 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.338.50 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments, 55.93 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.67 .88 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.206.35 Cotisations annuel! Annual assessments.206.35 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.157.90 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.175.00 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.175.00 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.483.03 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.77.67 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.34.38 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.411.22 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier. Parties do-parts of 5, 6.7 Parties de\u2014parti of 8, 9 49 50 86 87 88 221 345 Partie de\u2014part of 395 Partie de\u2014part of 396 502 592 686 Partie de\u2014part of 707 713 Partie de\u2014part of 795 Partie de\u2014part of 874 Parties de\u2014part of 116, 117 I 21.23.25.27 1661, 1563 19 1600.1602 1704, 1706.1708 1710, 1712.1714 1749.1751 1753, 1753a et\u2014and 1755 1757.1759 et\u2014and 1759a 2018, 2020 et\u2014and 2022 2029.2031.2033.2035 2473 2477.2479 2406.2408, 2410, 2412, 2414, 2416 2202, 2204, 2206.2208 2664, 2666.2668, 2670, 2672.2674.2676.2639.2639a et\u2014and 2641 2683, 2685.2687, 2689 2691, 2693 2448.2450 et\u2014and 2452 138, 140.142 Mont-Royal est\u2014cast.Adélaïde Davidson, venvr de St-Dominique.Mont-Royal est\u2014east Clarke.Clarke.Clarke.St-Urbain.St-Urbain.St-Urbain.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard.Clarke.Clarke.Clarke.Clarke.St-Urbain.St-Urbain.Waverley.Waverley.Waverly.Fairmount.widow of Hermas Corbcil.Adélaïde Davidson, veuve de-widow of Hernias Corlieil.Charles Fabien Vinet, jr.Charles Fabien Vinet, jr.Aubert Themens.Aubert Themons.\\ubert Themens.Joseph Ulric Meunier.Joseph Hevey, fils.Zenon Alarie.Rikle Shersheosky, épouse de wife of Max Zeliwiousky.Louis Cohen.Congrégation Thifereth Israel of Mile End.Alexis Plessis-Belair.Adolphe Turcotte.National Extracts Coy.John Côté.Joseph Damase Langevin.'{'\"i 4^ Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.24.06 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.152.54 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.152.54 Cotisations annueUes et spécial Annual and special assessments.12.72 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.12.72 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.12.71 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.639.32 Cot isations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.24.88 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.34.38 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.42.33 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.18.80 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.219.70 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.299.92 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.43.64 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.394.01 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.30.95 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.1,080.60 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessmenta AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street ¦ 33 3 fâ l-s go CB_ f8 3 CO il .23 3 > O ¦5*8 ¦j.g iM 8sS oSis * ° a «S lis .3 ' 5 ill 3 «a g .2\"S H 3° « fi 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 887 Partie de\u2014part of 905 974 975 976 1059-2 1059-4 1076-2 1076-3 1076-4 1076-12 Partie de\u2014Part of 1091 Partie de\u2014Part of 1098 I Partie de\u2014Part of 1101 2132, 2134, 2136, 2138, 2140 2328, 2330 81, 83 2734 2742, 2744 2770 2961, 2963 2868, 2870 et\u2014and 2870a i 2892 Esplanade.Esplanade.Esplanade.Esplanade.Esplanade.Lannes.Lanncs.Clarke____ Clarke.Clarke- Clarke____ St-Urbain.Clarke.Clarke____ NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Allan J.McDonald, Clarence A.McDonald.Emelia Karch, épouse de\u2014 wife of Sylva Frappier.Samuel Diamond.Samuel Diamond.Samuel Diamond.Alexina Lebœuf dit Laflamme veuve de\u2014widow of Louis Napoléon Denis.Alexina Lebœuf dit Laflamme veuve de\u2014widow of Louis Napoléon Denis.Humphrey Whitman et\u2014and Charles Ernest Whitman.Humphey Whitman et\u2014and Charles Ernest Whitman.Avila Pesant.Dominico di Césari.Annie Berlind, veuve de\u2014 wife of Isaac London.Solomon Gegoux.Joseph Boucher.267.14 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.138.11 141 142.09 142.73 Cotisations annueUes et spécial Annual and special assessments.23 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual a:.i special assessments.Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.54.58 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.84.84 46.01 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.46.01 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.131.00 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.46.47 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.6.15 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.45.46 Cotisations spéciales\u2014 I Special assessments.33.69lCotisations annuelles et spéciales\u2014 I Annual and special assessments.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier. 31 So 5 \"S £2 cj _ II 11 S fi i as Oo5 îi *3 \u2022£*5 o \u2014 11 1! il il il il il il il n il il il il il il 12 12 12 12 12 12 Partie de\u2014Part of 1107 1137 Partie de\u2014Part of 1150 1156-1 1156-2 1253 1349 1480 1481 1482 1639 1640 1641 1642 4-1 4-6 8, parties de \u2014 parts of 16,17,18 11, partie de part of 4 11, partie de \u2014 part of 31 13-26 2940, 2942 2756, 2758, 2760, 2762 et-and 2764 2865.2867 2921, 2923 et\u2014and 2925 3070, 3072 3118, 3120, 3122, 3124 3167 Clarke.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard Clarke.Clarke.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard.1489, 1491 1493, 1495 1497, 1499 1501,1503 233, 235 et\u2014and 237 1821, 8121a et\u2014and 1823 2150,2152,2154 2236, 2236a et-and 2238 2221, 2223 et\u2014and 2225 2258, 2258a, 2262, 2262a Clarke.St-Urbain.St-Urbain.Alexandra.Alexandra.Alexandra.Alexandra.Blvd.St-Joseph Ouest\u2014 St.Joseph West Blvd.Avenue du Parc\u2014 Park Avenue.Avenue du Parc\u2014 Park Avenue.Avenue du Parc\u2014 Park Avenue.Hutchison.Jeanne Mance.Ernest Poulin.Camille Bourdon.Dominico di Césari ct\u2014and Maria G.Jascenxo.Ernest Poulin.Camille Bourdon.Joseph Meloche.Peritz Cohen.Peritz Cohen.Sylvestre D'Ambrosio.Sylvestre D'Ambrosio.Sylvestre D'Ambrosio.Sylvestre D'Ambrozio.Blanche Auger, épouse de wife of Auguste Singer.Marie Louise Fortin, épouse de\u2014wife of Horace Dufort.L.Wilfrid Leduc.Emélie Karsh épouse de\u2014wife of Sylva Frappier.Edouard St-Auhin.Charles-A.Barnard.11 .39 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.34.60 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.46.01 Cotisât Hons spéciales\u2014 'Special assessments.10.48 Cotisations spéciales\u2014 'Special assessments.33.45 Cotisations spécial Special assessments.124.95 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.47.10 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.52.90 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.51.55 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.51.55 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.51.55 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.51.55 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.600.63 Cot isat ions annueUes\u2014 Annual assessments.311.18 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.2097.97 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.244.83 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.35.99 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.317.34 Cotisations annuelles\u2014 I Annual assessments. » VIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IM MO VE A BLES\u2014Continued Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes M S g o§ 5 a ** 8 §3 s* a) a> «5 IS S o s - .2 « » *g o & ijj 111 il* es I O ¦I fe ff?3 S \u2014 \"O 3 ~ .2S2 E if 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 partie de\u2014 part of 27 14-28 14-29 14-30 14-31 15-3 16-35 15-4 16-36 17-6 17-15 17-16 17-35-2 21 partie do -part of 9 22 partie de -part of 51 22 partie de -part of 25 22 partie de -part of 26 22 partie de -part of 26 2254, 2254a 2397, 2399.2401.2403 2389, 2391.2393.2395 2381.2383.2385.2387 2359,2361,2363,2365 2590, 2592 et\u2014and 2594 2525, 2525a et\u2014and 2527 Jeanne Mance.Hutchison.Hutchison.Hutchison.Hutchison.Park.Avenue du Parc.Avenue du Parc\u2014 Park Avenue.Avenue du Parc\u2014 Park Avenue.Avenue du Parc\u2014 Park Avenue.Hutchison.Hutchison.Avenue du Parc\u2014 Park Avenue.Avenue du Parc\u2014 Park Avenue.Avenue du Parc\u2014 Park Avenue.Charles-A.Barnard.Edouard Côté.Edouard Côté.Edouard Côté.Edouard Côté.Andrew Gentle Hall.Andrew Gentle Hall.Henri Brouillet.Wilfrid Duquette.Arthur Lafrance et \u2014 and Adélard Lafrance.Beno Berman et\u2014and William Galbraith.Edmond Mondehard.Edmond Mondehard.Edmond Mondehard.158.67 410.05 411.05 50.58 426.88 396.69 396.70 247.24 811.03 21.52 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles ct spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special asscasments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.< 'otisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles ct spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.367.14 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.163.26 163.26 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.163.26 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Laurier.Annual and special assessments.B Ci 12 ai s: \u2014 s) «2 h ^ a 1 « S£ 1 B.\"3 si\" B 8o il §2 .se- o ^ 2 \u2022a o fi 6.12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 22 partie do \u2014i.Avenue du Parc\u2014 par of 27 22 partio de \u2014 part of 33 22 partie de \u2014 part of 34 23-8 25-15 25-95 25-96 25 partie de -of 98 25 partie de -part of 112 25 partie do -part of 132 25-185 2708 200, 202, 204 2702, 2704 Park Avenue.Avenue flu Parc\u2014 Van Hornc.Avenue du Parc\u2014 Park Avenue.Hutchison.2830, 2832, 2834 2849, 2851 Jeanne-Mance.Jeanne Mance.Atlantique.Jeanne Mance.\u20222845c, 2845d et\u2014and 2845c Avenue du Parc\u2014 i Park Avenue.25-184 25-185 25-186 25-187 25-188 26-13 2845, 2845a et\u2014and 28456 2841, 2843 et\u2014and 2843a 2837, 2839 et\u2014and 2839a 2831, 2833 et\u2014and 2835 2825, 2827 et\u2014and 2829 3029 Avenue du Parc\u2014 Park Avenue.Avenue du Parc\u2014 Park Avenue.Avenue du Parc\u2014 Park Avenue.Avenue du Parc-Park Avenue.Avenue du Parc-Park Avenue St-Urbain.Edmond Mondehard Bcno Berman.Beno Berman.Succession\u2014Estate Mario Jo-[ séphine Amanda Fournier, \u2022 épouse de\u2014wife of Henri Pepin, Amélie Pepin, Louis Philippe Pépin.Henri Hogue.Henri Hogue.Bono Berman.Moscs Abrahamson, Jacob Basa vit?.Henri Hogue.Henri Hogue.Henri Hogue.Henri Hogue.Henri Hogue.Henri Hogue.Auguste Robert et\u2014and Julie Gravel, son épouse\u2014his wife.163.26 Cotisations annuelles H spéciales Annual and special assessments.772.29! Cotisations annuelles ot spéciales Annual and special assessments.291.09 C '.t isations annuelles et spéciales Animal and special assessments.171.10 Cotisations annuelles et spéciales Annual and special assessments.101.90.Cot [«al ions annuelles\u2014 Annual assessments.104 .73jCotisations annuelles\u2014 'Annual assessments.70.43|Cotisations annuelles et spéciales Annual and specitd assessments.112.30JCotisations annuelles et spéciales-jAnnunl and special assessments.125.45 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.125.45 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.129.74'Cotisations annuelles\u2014 Annua\"! assessments.129.74 Cotisation* annuelles\u2014 Annual assessments.lL'.'i.-15 Cotisations annuelles\u2014 Annual aMMBBU nt.«.125.45jCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.61.42 Cotisations annuelles et spéciales Annual and special assessments. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des reclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes «1 a -22 IS am a II ii « 9 .3> 8| M C l; £3 CD I 12 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 Partie de\u2014Part of 62 137 26-29 26-58 26-59 26-67 26-68 Parties de-parts of 154, 155 24 25 64 100, 101 119, 120 Partie de\u2014part of 129 147 3023, 3025, 3027, 3029 1573, 1575 et\u2014and 1577 118, 120, 122, 124 131, 133.135, 137.139 1872, 1874.1876, 1878 1932, 1934 et\u2014and 1936 1768.1770 1571,1573 St-Urbain.Waverley.Waverley.Waverley.Esplanade.Blvd St-Joseph ouest\u2014.St.Joseph west Blvd.Blvd St-Joseph ouest\u2014 St.Joseph west Blvd.Laurier ouest\u2014west Laurier ouest\u2014west Esplanade.Esplanade.Esplanade.Boulevard St-Laurent\u2014 St.Lawrence Boulevard.St-Dominique.Georges H.Labbé.Joseph Ulric Meunier.Léa Thouin, Léda Thouin____ Léa Thouin, Léda Thouin- John Louis Sabboth.Ls Dufour dit Latour.Ls Dufour dit Latour.Harvey Savard.Louis Adolphe Meunier.Amanda Goyette, épouse de\u2014 widow of Louis A.Meunier.Alexis Plessis-Bclair.Stanislas Rochon.Etta Albert, épouse de\u2014wife of Louis Lchrcr.Virgiles Carrière, Ernest Carrière.21.70|Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.186.78 Cotisations annueUes et spéciales-Annual and special assessments.33.44 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.120.42 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.10.38 Cotisations spéciales\u2014 Annual assessments.15.13 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.15.13 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.19S.63 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.104.79 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.54.73 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.155.33|Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.84.21.Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.407.48 24.68 Cotisations annuelles.Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.¦§1° 4iee 4171 4172 4185 4187 4188 4191 4192 419S 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 i es \"S f j 11 «s k m S * es a * = o c a «3 - i! p *S>o œO l'a .S .3 li .S o |.2 137 137 137 137 137 137 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 Partie de\u2014Part of 14 38 42 Partie de\u2014part of 251 Partie de\u2014part of 291 297-1 1 2 3 19 20 21 22-2 23-2 24-2 22-3 23-3 24-3 22-1 23-1 24-1 1611, 1015 ct\u2014and 1617 901, 906, 908, 910 938, 940 36, 38, 40, 42, 44 1465, 1467 et\u2014and 1469 1935, 1937 90 1959 1114, 1116 1110, 1112 1106, 1108 1126, 1128 1122, 1124 164 St-Dominique.Délia Collerette dit Bourgui- I gnon, épouse de\u2014wife of j Cléophas Lallongé.Coloniale.Coloniale Villeneuve.Hôtel-de-Ville.Cadieux.Laurier.Cadieux.Henri Julien.Henri Julien.Henri Julien.Henri Julien.Henri Julien.Henri Julien.Henri Julien.Henri Julien.Boulevard St-Joseph est\u2014 St.Joseph east Blvd.Blvd St-Joseph est\u2014 St.Joseph east Blvd.Blvd St-Joseph est\u2014 St.Joseph east Blvd.Solomon Zélicovitoh, Dora Stone, épouse de\u2014wife of Samuel Silverstone.Hormisdas Forget dit Depatie Yvonne Clément, épouse de wife of Olier Bruneau.Olympe St-Denis.veuve de\u2014 widow of Placide Allard.Théodore Carrière.Israel Lemieux 60.49 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Israel Lemieux.Israel Lemieux.Israel Lemieux.Israel Lemieux.Israel Lemieux.Israel Lemieux.Israel Lemieux.Israel Lemieux.Israel Lemieux.Israel Lemieux.17.00 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.282.51 7.12 14.87 159.20 10.14 10.14 6.41 62.74 63.78 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Animal assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.63.78ICotisations annuelles\u2014 Annual assessments.95.70 ( 'dtis.itions annuelles\u2014 Annual assessments.95.70 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.117.49 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.64.61 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.81.44 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier, Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Quartier Ward No du cadastre Cadastrai No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des îéclamations Nature of claims Noms das quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes So-CS eg fct \u2014 O a 11 |2 h -2 2 SI C o ois iU .£ *» o o a W* m «O g *- (d -a \"S 8 .So- 139\t25\t 139\t26\t154 139\t28\t1118,1120 141\t\t1076, 1078, 1080, 1082 125, 127, 129, 131, 133, 135 137\tParties de-parts of 305.306\t 137\tParties de-parts of 305.306,307\t1481, 1483, 1485.1487 Partie de\u2014part of 158\t\t904.906.908.910, 912.914, 916.918.920.922, 924.926.928,930,932 159\t4\t157.159 167\t15\t1027, 1029, 1031 167\t16\t1019, 1021 et\u2014and 1025 167\t17\t1011, 1016 170\t\t258 187\t\t1305 188\t\t 189\t\t1325 \t\t Blvd St-Joseph est\u2014 St.Joseph east Blvd.Blvd St-Joseph est\u2014 St.Joseph east Blvd.Henri Julien.Henri Julien.Blvd St-Joseph est\u2014 St.Joseph east Blvd.Hôtel-de-Ville.Henri Julien.Mont-Royal est.Mount Royal eabt.Israel Lemieux.Israel Lemieux.Israel Lemieux.Horace Chagnon.Ida Hébert, épouse de\u2014wife of Geo.Al lia ni Forest.Ida Hébert, épouse de\u2014wife of Geo.Albani Forest.Shoshie Luhush, veuve de\u2014 widow of Solomon Lubush.Eugénie Brennan, épouse de-wifc of Maxime Lesapc.Joseph Boucher.Joseph Boucher.Joseph Boucher- André Homer Gendron.Joseph Boucher.Joseph Boucher.Joseph Boucher.98.46 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.103.78 Cotisations annuelles\u2014 Animal assessments.78.69 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.149.70 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.18.71 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.47.01 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.635.94 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.132.21 Cotisations annuelles et spéciales.\u2014 Annual and special assessments.73.28 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.73.28 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.69.03 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.121.12 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.134.97 81.79 Cotisations annuelles et spéciales.Annual and sjx;cial assessments.Col i-at ions annuelles et spéciales-Annual and special assessments.133.33 Cotisation'! annuelles et sociales\u2014 Annual and special assessments.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.Laurier.co to O o o (p cd a g :q il il a \u2022|\"ô S a II \u2022o o is 9-2 2 ™ c s-a *D g SI © o S fil B °\"~ Site .o « fil Ifs o-£ S ¦C-3 o eo ««S es \"s h ci tO 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 150 48 150 48 150 49 49 51 51 51 61 1 2 3 4 5 18 30 31 63 64 28 65 27 66 26 22 23 364 365 392 451 205 206 Queen Mary Road Queen Mary Road Queen Mary Road.Projetée\u2014Projected Projetée\u2014Projected Projetée\u2014Proj ected Projetée\u2014Projected Projetée\u2014Projected Projetée\u2014Projected Projetée\u2014Projected Projetée\u2014Projected Projetée\u2014Projected Queen Mary Road.Queen Mary Road.Bourret Place.Bourret Place.Bourret Place.Lucy Place.Grégoire Meloche et\u2014and Joseph Meloche.Grégoire Meloche et\u2014and Joseph Meloche.Grégoire Meloche et \u2014 and Joseph Meloche.William Gamble.William Gamble.Robert H.Preston.Robert H.Preston.Robert-H.Prsston.Robert H.Preston.Robert-H.Preston.Robert H.Preston.Robert H.Preston.J.B.A.Bouchard.J.B.A.Bouchard.Eugène Douesnard, Eugène Douesnard.Elalie Bévillard.Exeluce Décarie.105.00|Cotisations annuelles et spécial Annual and s|>ecial assessments.67.78 Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments.24.80 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 'Annual and special assessments.SG.9(i < otisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.85.89 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.84.63 Cotisations annuelles et spécial Annual and sjiecial assessments.88.99 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.96.43 Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments.417.80 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments\u2014 106.69JCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.22.59 Cotisations annuelles\u2014 .Annual assessments.27.42 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.23.39 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.23.39 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.34.85 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.10.38 Cotisations annuelles»\u2014 Annual assessments.I 10.63|Cotisations annuelles\u2014 I Annual assessments.19.14 Cotisations annuelles\u2014 (Annual assessments.N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces ce to N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street If 121 3-2 s ill f SO \u2014' | T3 lia i§« 13 2 ^ «g-go \"SjS g !i5 ¦Slid ils .2 a^o s) Oh 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Partie de\u2014Part of 47 Partie de\u2014Part of 48 69 75-5.76-5.77-5.et\u2014and 78-5 75-2 76-2 77-2 78-2 92 93 146 147 213 214 215 216 Coolbrooke.Cool broke.Coolbrooke.Coolbrooke.Coolbroke.Coolbrooke.Coolbrooke.Coolbroke.Coolbrooke.Coolbrooke.Coolbrooke.Coolbrooke.Coolbrooke.NOTICE10F SALE OF IMMOVEABLES\u2014 Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fies municipalns Names of wards for municipal purposes The Corona Realty Company.; 49.41 The Corona Realty Company.Jane S.Youngson, épouse de-wife of Thomas Kirwood Clarke.Wilfrid J.Poupore.Wilfrid J.Poupore.Margaret Cummings.épousede \u2014wife of Duncan Munroe.Margaret Cummings,épouse de \u2014wife of Duncan Munroe.Robert H.Guest.Robert H.Guest.William J.Poupore.William J.Poupore.William Joseph Poupore.William Joseph Poupore Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.173.30 Cotisations annuelles et spéciales-jAnnual and special assessments.40.421Cotisations spéciales\u2014 I Spécial assessments.89.62{Cotisations annuelles Annual assessments.83.03 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.26.01 Cotisations annuell Annual assessments.66.45 Cotisations annuelles\u2014 A mimai assessments.22.58 28.66 27.08 27.08 27.08 27.08 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.-de Grâces g M N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces il se o \u2022si M \u2022*| C8 e« O ~Û>.C 9> *> XI J='y *\u2022 8 So5 ¦a18 eS~ B Isa o S oj5 « ^S£ 3 11 £ 52 52 62 Partie de\u2014part of 58 Partie de\u2014part of 60 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 217 218 210 21 22 23 65 66 67 68 69 76 77 124 125 126 538, 538a, 540, 542 528 Coolbrooke.Coolbrooke.Coolbrooke.Boulevard Décarie Boulevard Décarie EarnschfT.Earnscliff.Earnscliff.Earnscliff.Earnscliff.Earnscliff.Earnscliff.Earnscliff.Earnscliff.Earnscliff.Canada.Canada.Canada.William Joseph Poupore.Peter E.O'Brien.Peter E.O'Brien.Alfred Décarie, Joseph Sing-man.Philip P.Glickman, Philip Glickman et\u2014and S.L.Routtenberg Company.O.Massicotte «t Côté, Limitée\u2014Limited.O.Massicotte «t Côté, Limitée\u2014Limited.O.Massicotte & Côté, Limitée\u2014Limited.O.Massicotte A Côté, Limitée\u2014Limited.O.Massicotte & Côté, Limitée\u2014Limited.O.Massicotte «fc Côté, Limitée\u2014Limited.O.Massicotte & Côté, Limitée\u2014Limited.O.Massicotte «fc Côté, Limitée\u2014Limited.O.Massicotte ert Deny, Octave Archambault, Rév.L.Adolphe Sylvestre et\u2014and J.Edmond Mousseau.JOMpll Alphonse Mousseau, Gaspard Thouin, Armand Ouellette, J.Emile Desma-rai-, Pierre Sylvestre, ( \"uth-befet Denb, Octave Archambault,\" Rév.L.Adolphe Sylvestre et\u2014and J.Edmond Mousseau.Joseph Alphonse Mousseau, Gaspard Thouin, Armand Ouellette, J.Emile Desmarais, Pierre Sylvestre, Cuth-bert Dents, Octave Archambault, Rév.L.Adolphe Sylvestre et\u2014and J.Edmond Mousseau.9.52 130.39 120,95 106.60 31.90 30.4', 30.48 85.70 Cotisations annuelles-An nua! assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual asseasments.Cotisations annuelles Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Sp'-cial assessments.Cotisations spéciales-Spécial assessments.Cotisations spéciales-Special assessments.Cotisations spéciales-Spécial assessment-.N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces g Cri N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014SuiU NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of daims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Jfl &38 \"2 ts -> a *o g 2|j tS i I-2 IN o eu .o o s .ill .2 ¦ o Ilia 2 a S'a \"\u2022ft \u2022Sa C\"S I 142 142 143 143 143 149 149 149 149 964 966 4 4 5 24 136 136 137 Sherbrooke.Sherbrooke.Russell____ Russell____ Russell Sherbrooke Monkland.Monkland.Monkland.Joseph Alphonse Mousseau, Gaspard Thouin, Armand Ouellette, J.Emile Desmarais, Pierre Sylvestre, Cuth-bert Denis, Octave Archambault, Rév.L.Adolphe Sylvestre et\u2014and J.Edmond Mousseau.Joseph Alphonse Mousseau, Gaspard Thouin, Armand Ouellette, J.Emile Desmarais, Pierre Sylvestre, Cuth-bcrt Denis, Octave Archambault, Rév.L.Adolphe Sylvestre et\u2014and J.Edmond Mousseau.The Corona Realty Company.Alphonse Lamontagne.Joseph Zenon Patenaude Joseph Zenon Patenaude.Joseph Zenon Patenaude 38.09 38.09 6.38 The Corona Realty Company.6.38 The Corona Realty Company.1 6.38 265.56 25.52 25.53 145.46 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations annuel! Annual assessments.Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual asscasments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments' N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces co to N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces B2 a_ o « °2 CD CO II Q c g ©31 o ca 3 \u2014 «- o « o** *o -a 2 ul 111 _-\u2022£ 3 III Mi \"8 § o 149 149 151 151 151 152 152 152 152 152a 152a 152a 152 152 152 157 158 233 561 645 113 466 467 468 213 214 1387 470 471 469 Monkland.Monkland.Rosedale.King Edward Oak.Montclair.Terrebonne.Terrebonne.Terrebonne.Prince of Wales Prince of Wales Alexandra.Terrebonne.Terrebonne.Terrebonne.Joseph Zenon Patenaude.Joseph Zenon Patenaude.Barnabas Miles Pavey.Georgiana Connolly, épouse de\u2014wife of Irénée A.Am-yot.Evangéliste Major.Georges Gauthier.Alcide Rivost.Alcide Rivest.Alcide Rivest.Alex.G.Fowler Ross, Marie Sophie Charlebois, épouse de\u2014wife of Anselme Le-tang, Alexandre Orsali et\u2014 and John Alexander Henderson.Alex.G.Foster Ross, Marie Sophie Charlebois, épouse de\u2014wife of Anselme Le-tang, Alexandre Orsali et\u2014 and John Alexander Henderson.Archibald Hastie.Alcide Rivet.Alicide Rivet.Alicide Rivet.65.60 Cotisations annuelles et spéciales Annual and special assessments.44.29 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.29.35 44.22 90.12 17.58 27.74 27.48 34.96 8.36 8.36 7.44 24.46 25.52 34.04 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces >-M N.-D.de Grâces * N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number 88-8 !Jj 2*3-s 5 S til - \u2022\u2014.: 2 n8\"=» \" 1 e-s E ¦sis s s- .2 3 p«0^ - = -\"-\u2022 ¦_- - i- -z a a o - .3.3 o g .8-a ©s .2 a .So 156 156 156 156 156 156 156 156 162 165 168 169 168 169 170 214 215 216 217 218 219 220 220 444 121 790-1 789-1 788-1 787-1 706 764 707 390a 548 Bcnny.Benny.Bonny.Benny.Bcnny.Benny., Benny.Benny.Madison.Beaconsfield N.-D.de Grâces 222, 224 .Sherbrooke.Sherbrooke.iBelgravc.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Joseph Bergeron.Joseph Bergeron.Joseph Bergeron.Joseph Bergeon.Joseph Bergeron.Joseph Bergeron.Joseph Bergeron.Joseph Bergeron.William Henry Taylor.Edouard Napoléon Hébert.Gladys Seath, épouse de-wif t of William Ernest Baker.IFélix Dansereau.Félix Dansereau.Zenon Alarie.10.63JCotisations anmiollos\u2014 Annual assessments.10.63 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.10.65i|Cotisations annueUes\u2014 jAnnual assessments.10.63iCotisations annueUes\u2014 Annual assessments.10.63|Cotisations annuelles\u2014 'Annual assessments.lO.O^Cotisations annueUes\u2014 \u2022Annual assessments.10.63 10.63 36.75 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.20.52 Cotisations spéciales.\u2014 Special assessments 259.30 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.70.20 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.106.5S Cotisations annuelles Annual assessments.N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces g 178.20 Cotisations annuelles ot spéciales Annual and special assessments.30 N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâce N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces \u2022S-S K 2 « li a , 2£ 33 1?si - ~ b o 2 2 If- « 8 S o 1*1 g c£ T3£ a \u2014 » c is \"75 >, 3«J \"5^2 ¦851 Sop \u20222 S n i Ï2 § ¦ u 8 .2-ejO 170 170 170 171 171 171 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 175 563 658 659 67 Partie de\u2014Part of 66 Parties de-parts of 189 et\u2014and 190 191 Partie de\u2014part of 192 307 308 309 381 176 177 178 179 180 308 309 98 292,292a 294 316,318 Royal.Terrebonne.Terrebonne.Regent.Regent.Regent.Melrose.Melrose.Melrose.Melrose.Harvard.Harvard.Harvard.Harvard.Harvard.Oxtord.Oxford.Louis Philippe Courchcsne.Joseph Faille.Joseph Faille.Phillip Nucciarioni.Catherine McMullen, épouse de\u2014wife of Peter Michael McGolderick.Charles Gordon Kertland.J.-H.Albert Bohémier.J.-H.Albert Bohoniier.J.-H.Albert Bohémier.Merrill Edward Booth et-and Clarence David Booth.R.MacFarlane A Company, Limited\u2014Limitée.R.McFarlane & Company, Limited\u2014Limitée.R.McFarlane & Company, Limited\u2014Limitée.R.McFarlane «fc Company, Limited\u2014Limitée.R.McFarlane & Company.Limited\u2014Limitée.loseph Donat René.Joseph Donat René.14.89 44.00 37.52 48.68 Cotisât 175.23 143.89 14.89 14.89 14 V 177.03 16.98 16.98 16.98 16.98 16.98 15.90 37.30 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles ct spéciales Annual and special assessments.Cotisations annueUes et spécial Annual and special assessments.ions annlehes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisation-, annuelles et spécial' Annual and special assessments.Cotisations annuelles-Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 \\nnunl assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelle-et spéoiales-Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 S]>coial assessments.( 'otisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special asseasments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special asseasments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces g 1 N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street S-3J SI5 ¦8*1 SI* O 4) s \u2022sis is?\"g-S-3 is T3 S g- P- ° a 175 175 175 175 175 175 176 177 177 177 179 179 179 310 311 312 347 348 Parties de-parts of 460 et-and 461 49, 50, 51 177 178 181 21 22 709 370 170, 172, 172a.174, 176 176a, 178, 180, 180a.182.184, 184a Oxford.Oxford.Oxford.Sherbrooke.Sherbrooke.Oxford.Mardi.Old Orchard Old Orchard Old Orchard Addington.Addington.Western.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Joseph Donat René.Joseph Donat René.Joseph Donat René.Elzéar J.Desmarais.Elzéar J.Desmarais.Frances Marcia Hollis Rodden épouse de\u2014wife of Charles Depencier.Octave Valida Alfred Emond Joseph Albert Lafrance et\u2014 and Joseph M.Levesque.Joseph Albert Lafrance et\u2014 and Joseph M.Levesque.Joseph Albert lafrance et\u2014 and Joseph M.Levesque.Georgianna Connelly, épouse de\u2014wife of Irénée A.Amyot.Georgianna Connolly, épouse de\u2014wife of Irénée A.Amyot.jDandurand, Brodeur et\u2014and Boyer.37.30jCotisations spéciales\u2014 Special assessments.37.30 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.37.30 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.154.58 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.154.58 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.114.30 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.33.88 Cotisations spéciales\u2014 ISpccial assessments.38.74lCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.38.74 11.48 49.67 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.49.67 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.108.80 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces g C N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces C.-D.de Grâces N.-D.de Grâces 5288\t\t179\t210 5301\ttenant Notre-\t180\t114 5312\ta \u2014 '3 c\t181\t15 \tsa «2\t\t 5313\t\t181\t30 \t\t\t 5314\tde G e of t\t181\t31 5315\tal il\t181\t38 5317\t0 2 J, »\t181\t108 \tEJa \u2022?» _ o \u2014\t\t 5318\t2\t181\t115 5319\t.ville de of Mont ont real.\t181\t116 \t\t\t 5320\tde la parish of M\t181\t128 5323\t\t184\t410a 5333\t°«3\t184\t433a \t¦aTÎ ce 1 eu h ce ï\t\t 5334\t\t184\t434a 5361\ta^ g s a !\t189\t15 \ts.*\t\tParties de-parts \t\t\tof 17 et-and 18 \tg-a M-\t\t 5362\t|2 8 &.20\t189\t141, 142 5363\t¦S||\t189\t140 5366\t\t189\t196 \ta fi\t\t 5367\t\t189\t197 20, 22 129, 131 86 5037, 5039 et-and 5041 G rouard.Botrell.Prud'homme.Prud'homme.Prud'homme.Prud'homme.Boulevard Décarie.Boulevard Décarie.Boulevard Décaric.Boulevard Décarie.Marlowe.Northcliffe.Northcliffe.Claremont.Sherbrooke.Sherbooke.Grey.Grey.Elzéar Ilcnoit.Marc Décarie.Joseph Prud'homme.Barthélemi Lefebvrc.Barthélcmi Lefebvre.Joseph Roger Lesage.Joseph Roger Lesage.Barthélemi Lefebvre.Barthélemi Lefebvre.Jos Prud'homme.Anglins Limited\u2014Limitée.Aristide M.Joncas.Aristide M.Joncas.Alexandre Duranceau, Charles Duranccau,Edgar Tremblay et\u2014and Joseph A.Francœur.Thomas Coggins.Thomas Coggins.François-Xavier Décarie.François-Xavier Décarie.37.19 Cotisations annuelles ct spéeiaios Annual and special assessment-.13.07 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.49.92 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.58.43 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.82 99 Cotisations annuell Annual assessments.113 62 Cotisations annuelles ct spéciales\u2014 Annual and special assessments.94.41 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and spécial assessments.82.90 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.137.03 Cotisations annuelles Annual assessments.45.20 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.83.58 Cotisations annuelles et sr>éeialcs\u2014 Annual and special assessments.32.33 Cotisations sociales\u2014 Special assessments.32.34 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.166.46 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.840.09 139.90 7.96 7.96 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.N.-D.de Grace.N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces w N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue St eet If 198 198 198 198 198 198 1698 1698 1698 120 121 122 218 219 226 62 63, 64 144 35, 37.39, 41 Northcliffe.Northcliff.Northcliffe.Brillon.Brillon.Brillon.Notre-Dame Victor Hugo Troye.NOTICE OF SALE OP IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed p op ieto.Montant Amount claimed Natu e des éclamations Nature of claims Noms des qua -tie s pou fins municipales Names of wa d for municipal purposes Gustave Emile Despocas.Gustave Emile Despocas.Gustave Emile Despocas.Anatole Décarie.Anatole Décarie.Gustave E.Depocas.Elisée Cordeau et\u2014and Emile Cordeau.Elisée Cordeau et-and Emile Cordeau.Succession-Estate Geo.W.Stephens.31.38 Cotisations spécial Special assessments.31.38 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.31.38 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.10.29 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.10.29 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.41.52 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.29.15 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.136.50 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.13.80 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces CO N.-D.de Grâces 10 N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces si* 1JJ 111 IE ag a » a œ-g « !k 9 I £ m \"5*2- O o lis.lui PL.Partie de\u2014part o\t\t1652.1654, 1656.1658.\tSt-Patrice\u2014St.Patrick.3518\t\t1660, 1662 et\u2014and 1664\t 3929\t10, 10a\t2102\t 3999\t2\t248, 250\t 4027\t1\t\tChampigny.4027\t2\t\tChampigny \t\t\t 4042\t6\t\t 4043\t6, 7, 8 et\u2014and 9\t\t 4049\t1\t335,337 \u2014\t\u2022 4048\t1\t\t 4035\t1\t\t 4040\t4\t1\tBrisuet.Mary Comabrs alias O'Connors, veuve de\u2014widow of Michael Hughes.The Security Land Company, enregistrée \u2014 registered Jean Louis Frigon, Armand P.Raymond, Charles E.Martin, Charles Bruché-i et\u2014and Alfred Desnoyers.Arthur Guérin.Henri Pigeon, Rose Pigeoot Arthur Pigeon, Catherine Pigeon, épouse de\u2014wife of Joseph Ryan.Henri Pigeon.Rose Pigeon, Arthur Pigeon, Catherine Pigeon, épouse de\u2014wife of Joseph Ryan.The Trustees of the St-Paul congregation of the Methodist Church.Joseph Eugène Sénécal.127.25 54.58 Corinne Mongenais, épouse de\u2014wife of Joseph Hyacinthe Bastien.60.90 12.20 12.20 33.85 66.45 96.53 Cotisations annuell Annual assessments Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel: CD CO CO St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel. AVI8 DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street \"5 \"3 *^ *2 S s a a œ O Oj3 «08 lu age ?£a « t \"£¦3 fil Ifs «Ë tel § a c III IE .°\"3 s » s a O n \u2022siii *S.a\"o Parties de \u2014 parts of 3615, 3616 3615 3616 361 36 3617 3662 3663 3697 3705 19 42 550 24 662 572, 573 171, 173 et\u2014and 175 145, 145o, 147, 147a 94 St-Pntrice\u2014St.Patrick.Jogues.Dumas.Mazarin.Mazarin.Daragon.Ha m i ton.145, 145a, 147, 147a, 1476, 147c, 147d, 147c, 147/, 149, 149a, 149b, 149c, 149d, 149c 149/, 151a, 1516 109, 109a, 111, 111a, 1116, 111c llld 111c, 113.113a, 1136, 113c, 115, 115a Hamilton.Hamilton.Hamilton.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire corisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Natuie des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Montreal Factory Lands Limited\u2014Limitée.Calixte Corbeil.Henri Gagnon.Albert Aubertin.Oswald Chaput.Arthur Lemieux.Succession\u2014Estate Duncan E.Bowie, The Viewmon Land Company, Géraldine A.Brunet épouse de\u2014wife o Donald McTaggart, Lilian M.Brune , épouse dt wife of Herbert Hogle.Succession - Estate Duncan E.Bowie, The Viewm nt Land Company Géraldine A.Brunet.épous de\u2014wife of Donald McTaggart, Li Han M.Brunet, épouse de\u2014 wife of Herbert Hogle.Joseph Alphonse Henri De-quoi.Arthur Lemieux.622.74 78.30 10.00 34.43 11.53 43.68 66.37 88.39 490.95 293.98 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes et .-pédales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriei.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel.eo St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel. tu - ti \"5 a t I is o a gl ¦g-s il W £ ai «g g oj3 1 ill ¦S ° b 3 -2\"o ¦§¦8 s us h'cj a 3731\t1\t104\t\t\t31\t48\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.\tSt-Gabriel.\t\t\t\t\t\t\t\t 3747\t2, 3\t272, 274\t\t\t134\t«J0\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.\tS.Gabriel \t\t\t\t\t\t\t\t 3759\t\t\tHamilton.\tSu cession - Estate David A.Ansell.The Viewmont Land Compaiy, Ger ildine A Brunot, épouse de\u2014wife of D.Donald McTaggart, Li lian M- Brunet, épouse de\u2014 wife of Herbert Hogle.\t71\t52\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special asses monts.\tSt-Gabriel.\t\t\t\t\t\t\t\t 3804\t\t\tRandot.\tEdmond Nlondch'ird\t11\t87\tCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\t \t\t\t\t\t\t\t\tSt-Gabriel.3861, 3862\t\t449\tBcaulieu\tHenry C Price et\u2014and Walter L.Price.\t164\t41\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special asses ments.\tSt-Gabriel.\t\t\t\t\t\t\t\t Partie de\u2014part of\t\t413,415\t\tSiméon Rivet et\u2014and Hec'or\t68\t90\tCoti ations annuelles et spéciale \u2014 Annual and special assessments.\tSt-Gabriel 3867\t\t\t\tRivet.\t\t\t\t 3901\t2\t109,111\t\t\t56\t77\tCotisations annuell -s\u2014\tSt-Gabriel.\t\t\t\t\t\t\tAnnual assessments.\t 3912\t51, 52\t68, 60\t\t\t25\t23\tCotisations spéciales\u2014 Special assessments.\tSt-Gabriel.\t\t\t\t\t\t\t\t 3912\t155\t295\tBlvd Monk.\tArthur Cousineau.\t99\t82\tCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\tSt-Gabriel.\t\t\t\t\t\t\t\t 3912\t327\t19.19a\t\t\t181\t19\tCotisations annuelles\u2014 Annual assessments.\tSt-Gabriel.\tPartie de-Part of 328\t\t\t\t\t\t\t 3912\t407\t18\tA.\t\t19\t70\tCotisations spéciales\u2014 Special assessments.\tSt-Gabriel.\tPartie de - Part of408\t\t\t\t\t\t\t 3930\t5, 6\t21, 23, 25, 27, 29, 29a\tLe Caron.\t\t275\t75\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.\tSt-Gabriel.\t\t\t\t\t\t\t\t 3930\t53\t72, 74\tDe Villiers.\tLa Compagnie des Terrains Suburbains de Montréal.\t66\t17\tCotisations annuelles\u2014\tSt-Gabriel.\t\t\t\t\t\t\tAnnual assessments.\t 3930\t00, 61\t100.100a, 102, 104, 104a\tDe Villiers.\t\t8\t68\tCotisations spéciales\u2014 Special assessments.\tSt-Gabriel.\t\t\t\t\t\t\t\t 3930\t73, 74, 75\t152.152a, 1525, 164, 154a,\tDe Villiers.\t\t421\t4N\tCotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.\tSt-Gabriel.\t\t1546, 156, 156a, 156b, 158, 158a.160\t\t\t\t\t\t AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suit» NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014-Continued Quartier\tNo du cadastra\t\tNo de la rue\tRue\tPropiiétaire cotisé\tMontant\tNature das réclamations _ \u2022\t_\tSubdivision\t_\t_\t_\t\u2014\t\u2014 \t\t\t\t\t\tAmount\t Ward\tCadastral No.\t\tStreet number\tStreet\tAssessed proprietor\tclaimed\tNature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes \u2022o o o fil Sri fig.\"8-a 3'3, -9-3 IÎÏ1 8M all \u2022 a a \u2022o S \u2022 o 3030 3930 3930 3930 3930 3930 4609 4669 4669 4674 4674 147 173 partie de\u2014 part of 174 193, 194, 196 209 219 276 10.11 93 169, 170 25, 26 203 149, 149a, 161, 151a, 163, 153a, 165, 155a, 157.167a, 159, 159a 173, 175 213, 213a, 2136, 215.216a.2156 146, 148 2109 Le Caron.De Villiers.De Villiers.261, 263, 263a 149 81 De Villiers.De Villiers.DeNonville.Jacques Hertel.Jacques Hertel est\u2014east.Eddie.Woodland.Springland.Arthur Pigeon.Joseph Taillefer.Raoul Aulicrtin.Damien Oratton.Napoléon Lavoie.Adélard Bisson.La Compagnie des Terrains Suburbains de Montréal.J.E.Oswald Chaput.Joseph Robidoux.John Seguin.Joseph Charles alias Cyprien Grenier.18.95 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.11.16 Cotisations spéciale \u2014 Special assessments.423 47 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.59.76 Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments.165.82 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.80.60 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.8.03 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.29.53 Cotisations annuelles et spécial' Annual and special assessments.25.22 Cotisations spéciales\u2014 Speci 1.1.assessments.46.02 Cotisations annuelles et spécial' Annual and special assessments.25.60 Cotisations annuell Annual assessments.St Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel.St-Gabriel. £083 6684 6685 5600 5605 5696 6709 5710 5720 5727 5741 5742 5745 6746 6747 5748 5749 a o ¦si s s as eSv.8 ° ï* 11 if 3 a à* lî \u2022S 13 ¦OcQ Ifi 'il -a\" « o 228 228' 228 228 228 228 228 228 228 230 245 245 246 246 246 246 246 48 58 59 188, 189, 190 et \u2014and 191 200 et-and 201 202 et-and 203 489 490 678, 679 etr-and 680 10 11 et partie de-and part of 12 17 248 249 250 251 285 901 6144 et-and 6146 6158 6164 910 6410, 6412 et\u2014and 6414 6468 St-Charles.Blvd Gouin.w Blvd.Gouin.Avenue Péloquin Avenue Péloquin Avenue Péloquin Avenue Péloquin Avenue Péloquin Boulevard Gouin Durham.Lajeunesse.5475 et\u2014and 5477 Bern.Berri____ Bern____ Bern.Berri.St-Denis.Rosina Lamarre, épouse de wife of Elzéar Pigeon.Henri Sauriol.Henri Sauriol.Achille Billet et\u2014and Raymond Billet.Achille Billet et\u2014and Raymond Billet.Achihe BUlet et-and Raymond Billet.DUe Stishea Galub.Dlle Stishea Galub.Zéphirin Gauthier.Pierre Lauzon.Alexandre Poulin, Onésime Bellerose, Ernest Poulin et \u2014 and Richard S tarn p-fler.Léo Levasseur.Ludger Nault.Ludger Nault.Ludger Nault.Ludger Nault.Marie Rose Philomène Joncas veuve de\u2014widow of Ludger Lapointe.37.29|C«tisatiops annuelles\u2014 Annual asesessments.30.78 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.7.44 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.7.44 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.7.44 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.7.44 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.JAhunt«c-Bor-¦ deaux.iAhuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuotsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.O CO ^1 13.59.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.13.60 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.126.51 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.83.99 Cotisations annuelles ct spéciales\u2014 Annual and special assessments.83 99 Cotisations annuelles et spéciales Annual and special assessments.6.38 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.6.38 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.135.52 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.101.08 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.34.27 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Ahuntsic-Bor-deaux.15.52 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments. AVTSJDE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Node la cédule Schedule No.Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street 6755 5766 5760 5765 5766 5767 5770 5771 6772 6773 6774 5775 6776 5777 5778 S*8 «8 g 2 a il B*r S2 ik 1\" s 1 p \u2014 cS o ¦al cci g cd * » o .2 (3 I c Ph 247 247 247 247 247 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 257 257 12 13 73 174 175 34-26 13-2 34.40 24-1 34-41 24-2 34-47 31-1 34-51 33-1 34-52 33-2 34-54 14-1 34-55 14-2 12 13 Henri Julien Henri Julien Henri Julien Blvd Gouin Blvd Gouin Henri Julien Henri Julien Henri Julien Henri Julien Henri Julien Henri Julien Henri Julien Henri Julien Laverdure.Laverdure.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pourlfins municipaes Names of wards for municipal purposes Henry Weinfield.Henry Weinfield.William Armstrong et\u2014and Alfred Ward.Henry Weinfield.Henry Weinfield.DlleGertrude Forest.Dlle Gertrude Forest.Dlle Gertrude Forest.Dlle Gertrude Forest.Narcisse Fotest.Dlle Gertrude Forest.Dlle Gertrude Forest.Dlle Gertrude Forest.Hector Paiement Hector Paiement.28.08 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.28.08 20.43 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuell Annual assessments.53.19 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.80.84 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62 7.66 7.6fi Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahun tsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsie-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.\u2022 Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahunt8ic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux. 08 j I o s \u20ac> \u2022O *2 OJ * B a 5 >¦ i* H M « S* 2 il ¦3 = çcq 257 252 261 262 261 262 261 262 261 262 261 262 261 262 261 262 261 262 261 262 261 262 262 262 262 262 262 14 25 27 26 28 27 29 28 30 29 31 30 32 31 33 32 34 33 35 34 36 241 242 453 454 455 456 Laverdure.St-Laurent-St.Lawrence.St-Laurent-St.Lawrence.St-Laurent-St.Lawrence.St-Laurent-St.Lawrence.St-Laurent-St.Lawrence.St-Laurent-St.Lawrence.St-Laurent-St.Lawrence.St-Laurent-St.St-Laurent-St.Lawrence.Lawrence.St-Laurent-St.Lawrence St-Laurent-St.Lawrence St-Laurent-St.Lawrence.Clarke.Clarke.Clarke.Clarke.Hector Paiement.Corinne Prévost.Corinne Prévost.Corinne Prévost.Corinne Prévost.Corinne Prévost.Angélique Barbeau, épouse de \u2014wife of Charles Arsène Prévost.Angélique Barbeau, épouse de \u2014wife of Charles Arsène Prévost.Angélique Barbeau, épouse de \u2014wife of Charles Arsène Prévost.Angélique Barbeau, épouse de \u2014wife of Charles Arsène Prévost.Angélique Barheau, épouse de \u2014wife of Charles Arsène Prévost.Joseph Louis Henri Marcil.Joseph Louis Henri Marcil.Marie Rochon, épouse de\u2014 wife of Hector Paiement.Marie Rochon, épouse de\u2014 \u2014wife of Hector Paiement.Marie Rochon, épouse de\u2014 wife of Hector Paiement.Marie Rochon, épouse de\u2014 wife of Hector Paiement.7.66 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 19.47 19.47 19.47 Cotisations anuuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.12.34 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.19.47 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.A h u n t si c - Bordeaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahunt«c-Bor-deauz.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deauz.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor- ^ deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annuai assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal pui poses JSS \"| M a m 2 * o S! es _r a ® a* à H o g i cd lu a 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 478-1 478-2 479-1 479-2 480-1 480-2 481-1 481-2 482-1 482-2 483-1 483-2 614 615 516 617 634 635 636 637 Clarke.Clarke.Clarke.Clarke.Clarke.Clarke.Clarke.Clarke.Clarke.Clarke.Clarke.Clarke.Clarke.Clarke.i.\tHector Paiement.\t \t \t \tHector Paiement.\tMarie Rochon, épouse de\u2014 wife of Hector Paiement.Marie Rochon, épouse de-\u2014 wife of Hector Paiement.Marie Rochon, épouse de\u2014 wife of Hector Paiement.Mario Rochon, épouse de\u2014 wife of Hector Paiement.George Smith.\t \t \t \t .\t \t \t \t 40.12 40.12 40.12 43.44 43.44 62.61 19.47 19.47 19.47 19.47 6.38 6.38 6.38 6.38 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spécial' Annual and special assessments.Cotisations spécial Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuell Special assessments.Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations annuelles Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuell Annual assessments.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahunt sic-Bordeaux.Ah un tsie-Bordeaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntric-Bor- ^ deaux.o Ahuntsie-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.A hunt sic-Bordeaux.Ahuntsio-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux. I eu I I a e S il «s g* 20 11 il 'S * 11 o a 11 *£ \u202203 c-ç 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 263 263 263 264 268 «38 630 640 64] 642 643 644 645 646 647 14 28 50 63 280 Clarke Clarke Clarke Clarke Clarke Clarke Clarke Clarke Clarke Clarke St-Urbain St-Urbain St-Urbain St-Hubert Lamothe George Smith.George Smith.George Smith.George Smith.George Smith.George Smith.George Smith.George Smith.George Smith.George Smith.Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne, \"Pierre J.Champagne & Cie\".Marie Rose Lal>elle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne, \"Pierre J.Champagne & Cie.\" Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne, \"Pierre J.Champagne & Cie.\" Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne, \"Pierre J.Champagne 4 Cie.\" Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne, \"Pierre J.Champagne & Cie.\" 6.38 Cotiaations annuelles\u2014 Annual assessments.4.25 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.4.25 Cotisations annueUes Annual assessments.4.25 Cotisations annueUes\u2014 Annual assea«mcnts.4.25 Cotisations annueUes\u2014 Annual asessments.Ahuntsic-Bor-deauz.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-dcaux.Ahuntsic-Bor-deaux.CO 6.38 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.6.38 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.6.38 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.6.38 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.6.38 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.6.38 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.6.38 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.6.38 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.6.38 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.4.25 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Ahuntsic-Bor-deaux.A hunt sir-Bordeaux.Ahuntsic-Bor-deaux.A hunt sic-Bordeaux.Ahuntsic-Bor deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-Heaux.Ahuntsic-Bor-deaux. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street .-ê.â -\"S fi g » «s a il il il B§ M SI s - 3S.ltd ¦Si» .2 o >> 268 268 268 268 268 268 277 276 277 317 341 358 380 417 441 20 14 882, 883 et and 884 Lamothe.Lamothe.Lamothe.Lamothe.Lamothe.Lamothe.Blvd Gouin.Blvd Gouin.NOTICE OF SA^E OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Natuie of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne, \"P.J.Champagne & Cie.\" Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne, \"P.J.Champagne \u2014 Cie.\" Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne, \"P.J.Champagne & Cie.\" Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne, \"P.J.Champagne & Cie.\" Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne, \"P.J.Champagne & Cie.\" Marie Rose Labelle, épouse de \u2014wife of Pierre J.Champagne, \"P.J.Champagne & Cie.\" Olivier Dubois.Joseph Leblanc.4.25 4.25 4.25 3.84 3.84 3.84 58.38 Cotisations annueUes\u2014 Animal assessments.Cotisations annueUes Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual asessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual ascsessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.72.95Cotisations annueUes\u2014 I Annual assessments.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuutsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux. J. | -S to aJjCQ^ bj O S8 «\u2014 \"O ¦3 *f og If fil é ft* 8 ft.2-3 ^ § S m » ® «S I c II oj' B 03 s ^¦5 .20 111 03 OS H* H SStga .2 a os 2 o «ICI .2- ° o h4'S ft S 287 287 287 301 301 323 323 323 323 323 342 344 344 350 350 17 18 739 169 170 5 6 56 58 74 et\u2014and 8s 125 294 295 696 697 1081, 1083 3814, 3816 6401 6380 Lajeunesse.Philias Malo.Lajeunesse.Philias Malo Blvd.Crémazie.Emile Albert Dumont, Lucien Albert.J.Dumont et\u2014and Marie Reine Dumont.Bois-de-Boulogne.Bois de Boulogne.Valmont.Valmont.Pasteur.Pasteur.Pasteur.St-Laurent-St.Lawrence.Marguerite Bourgeois- Marguerite Bourgeois.Stewart.Stewart.J.E.Oswald Chaput.J.E.Oswald Chaput.Marie Henriette Picard.veuve de\u2014widow of Joseph Gagnon.Marie Henriette Picard, veuve de\u2014widow of Joseph Gagnon.Anastasie Gagnon, épouse de-wife of Damien Cyr.Fanny Zannisky, épouse de\u2014 wife of Israel Levinson.Euclide Legault.Ernest Poulin.Sarah Jane Proctor, veuve de-widow of Robert Alexander.Sarah Jane Proctor, veuve de-widow of Robert Alexander.Charles Robertson.Charles Robertson.23.88 23.88 48.83 28.25 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.28.25 21.60 26.50 90.47 105.65 70.14 11.70 8.26 8.26 6.35 6.35 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spécial' Annual and special assessments Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Animal and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ah un tsi c-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deairx.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahun t sic-Bordeaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntàc-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux. AVIS DE VENTE D'IM MEUBLES\u2014Suite Quartier Ward ^J5\"3 o\" ¦2 3'5-S fi 4 CO a'3-s es S es ill Ils m 330 I T No du cadastra Cadastral No.489 489 489 489 489 ¦ 489 489 490 641-1 641-1 641-1 641 641 Subdivision Partie de\u2014part of 66 145 177 187 et\u2014and 186 310 311 No de la rua Street number 3230 3227, 3229 et\u2014and 3229a 2610, 2512, 2512a, 2612b, 2514 ct\u2014and 2514a 3357 et\u2014and 3359 3361, 3363 et\u2014and 3863a 160 69 67 73 3-61 3-88 Rue Street Chateaubriand St-Hubert.St-Hubert.Chateaubriand St-Hubert.St-Hubert.319 et\u2014and 320 2580, 2580a, 2580fc, 2580c et\u2014and 2580a 935 3441, 3443 et\u2014and 3446 66, 67, 69 3113,3115 Chateaubriand Villeray.8t-André.Grande.Grande.Grande.Jeanne-Mance Jeanne-Mance NOTICE OF SALE OF 1M MOVABLESE\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes William Meikle.Georges Brisson.Paul Olivier Coulombe.Thomas Brault.Ernestine Rousseau, veuve de\u2014widow of Joseph Via-teur Bastien.Ernestine Rousseau, veuve de\u2014widow of Joseph Via-teur Bastien.Rémi Beaulieu.Télesphore Alfred Primeau.William Pelletier.Paul-Olivier Coulombe.Thomas Kinnon.Dlle A thai ie Leriche.Henry Gordon Nivin.83.78 52.11 210.18 297.97 134.77 154.31 178.21 99.31 44.27 60.10 47.75 19.31 16.92 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales.Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et psécial Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special asesssments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Ahuntsic-Bor-deauz.Ahuntsic-Bor-deauz.Ahuntsic-Bor-deauz.Ahuntsic-Bor-dcauz.Ahuntsic-Bor-deauz.Ahuntsic-Bor-deauz.Ahuntsic-Bor-deauz.Ahuntsic-Bor-deauz.Ahuntsic-Bor-deauz.Ahuntsic-Bor-deauz.Ahuntsic-Bor-deauz.Ahuntsic-Bor-deauz.Cotisations annuelles\u2014 Annual aascssments.Ahuntsic-Bor-deauz. \u2022So JS-8 S3 1 s « is h if 041 642 642 643 2580 2629 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2643 2643 2643 2643 2643 2643 3-89 51 52 92 28 49 108, 109 276 329 361 617 150 151 152 153 206 207 104 3642, 3644, 3646 3281, 3283 3586, 3588 2701, 2703, 2705 935, 937, 939, 941, 943, 945 947, 949 3109 Joanne-Mance.Grande.Grande.Casgrain.Berri.Lajeunesse.St-Hubert.DeChâteaubriand Françoise Barry.Des Belges.Des Belges.DeChâteaubriand St-Hubert.Drolet.Drolet.Drolet.Drolet.Berri.Berri.Henry Gordon Nivin.Isabella McRae, épouse de\u2014 wife of Thomas C.Lidstone Isabella McRae, épouse de\u2014 wife of Thomas C.Lidstone Philias Malo.La Compagnie de Prêt Mutuel, Limitée\u2014Limited.Onésime Hamelin et Narcisse Marchand.and Zéphirine Lamarche, veuve de\u2014widow of Willi m Des-longchamps.Oscar Latreille.Euclide Roy.Ephrem Perrault.Louis Adolphe Plante.Parmélia Bélanger, épouse de\u2014wife of P.Laçasse.Joseph Hector Tessier.Joseph Hector Tessier.Joseph Hector Tessier.Joseph Hector Tessier.Joseph Hector Tessier.Joseph Hector Tessier.16.92 31.76 44.14 144.64 48.07 39.35 104.12 203.24 6.60 47.28 6.39 15.39 7.65 7.65 7.66 7.65 41.27 41.27 Cotisations annuelles\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual assessments.deaux.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual and special assessments.deaux.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual and special assessments.deaux.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual and special assessments.deaux.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual and special assessments.deaux.Cotisations annuelles\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual assessments.deaux.Cotisations annuelles\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual assessments.deaux.Cotisations annuelle»\u2014 et spéciales Ahuntsic-Bor-Annual and special assessments.deaux.Cotisations annuelles\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual assessments.deaux.Cotisations annuelles\u2014 Ahuntsic-Bor- Aruinai assessments.deaux.Cotisations annuelles\u2014 Ahuntsie-Bor- Annual assessments.deaux.Cotisations annuelles\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual assessments.deaux.Cotisations annuelles\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual assessments.deaux.Cotisations annuelles\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual assessments.deaux.Cotisations annuelles\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual assessments.deaux.Cotisations annuelles\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual assessments.deaux.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual and special assessments.deaux.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Ahuntsic-Bor- Annual and special assessments.' deaux. AVI8 DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Node la eédule Schedule Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street 6486 6487 6488 6497 6603 6510 6511 f512 6513 6614 6515 6524 6538 Si O O -s \u2022s >, il a » ¦a g IS fi 3 £00 5- a.g 5 5 \u201e S T3 o «a-g 1 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2645 208 209 210 538 Partie de\u2014part of 537 1269 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2553 76 3114, 3116 3501, 3503, 3505 Berri.Berri____ Berri- DeGaspé.DeGaspé.Berri- Berri.Berri____ Berri- Berri.Berri____ St-Denis.Berri- NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quar tiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Joseph Hector Tessier.Joseph Hector Tessier.Joseph Hector Tessier.Raoul Alexandre Gingras Napoléon Bélanger.Allan J.MacDonald.Allan J.MacDonald.Allan J.MacDonald.Allan J.MacDonald.Allan J.MacDonald.Allan J.MacDonald.The Crystal Spring Land Company Limited-Limitée.Joseph Hector Teasier.41.27 41.27 41.27 74.85 107.88 29.23 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spécial Annual and spécial assessments.Cotisations annueUes et spécial Annual and special assessments Cotisations annueUes et spécial Annual and special assessments Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations annuelle et spéciales\u2014 Annual and special assessments.29.23 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments 29.23 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.29.23 Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments.29.23Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.29.23 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and special assessments.34.05 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.33.00 Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahunt sic-Bordeaux.Ahuntsic-Bor-deaux./ Ahuntaic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.A hunt sic-Bordeaux.Ah vntsic-Bordeaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntsic-Bor-deaju. IJRII* 1 1-Sn3 S'3 .2 g *P* 2 o iflli Sllia j 3-s-S o ¦o a-^o+s IIS o 2 Ph 2.ts °m ¦2*8.2.s - - - ¦°§° \u2022S g* a-5 S3 I s| o .or T3 0j O 3 \"~ .2-2^ c >» *> o » P.*; £Pht3>-5 3 Ph 264S 2645 2645 63 53 53 53 53 Partie de\u2014part of 99c Partie de\u2014part of 10 21 21 77\t\t 125, 126,\t127\t3441 138\t\t 8\t\t 9\t\t 39\t\t 40\t\t 41\t\t \t\t 11\t\t150, 152, 154, 156, 158 25\t\t 26\t\t 41\t\t \t\t 78\t\t 81\t\t Berri.Berri.Berri.Joseph Hector Tessier.Claude Charles Reed.J.-E.Oswald Chaput.Blvd Ste-Marie\u2014 St.Mary's Blvd.Blvd Ste-Marie\u2014 St.Mary's Blvd.Plantagenet.Plantagenet.Plantagenet.Du Centre.Edmond Mondehard.Edmond Mondehard.(Succeasion \u2014 Estate William Gariepy.Succession \u2014 Estate William Gariepy.Succession \u2014 Estate William Gariepy.Arthur Courchesne.Villemarie Notre-Dame-Est-East.Notre-Dame-Est-East.Ste-Catherine-Est-Eas?Notre-Dame-Est-East.Lacordaire.Lacordaire.Clara Pineault, épouse de\u2014 I wife of Honoré Brodeur.Joseph Ulric Meunier.Joseph Ulric Meunier.ayantes Gavaris.Charles Austin Barnard.Jos.-Antoine Hilaire Hébert.Marie Aida Gamcau, épouse de\u2014wife of J.B I).Légaré, Prosper Dion et\u2014and Ludger Legault.33.00 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.68.55 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.26.28 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.34.04 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.40.43 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.57.44 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments 57.44 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.57.44 Cotisations annuell Annual assessments.29.78 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.12.80 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.54.78 Cotisations annueUes et spéciales-Annual and special assessments.54.78 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.50.63 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.286.00 Cotisations annuelles et spéciales-Annual and special assessments.13.32 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.13.32 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Ahuntsic-Bor-deaux.N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces N.-D.de Grâces g> N.-D.de Grâces Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Ahuntsic-Bor-deaux.Ahuntàc-Bor-deaux. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suit» Node la eédule Schedule No.6649 6661 6652 6653 6654 6656 * 6657 6658 0659 Quartier Ward Va il g «s 8 a «a §2 S.S S o 1§ Ph o si ¦5».\u2022-Pn-g S i § II?» a -n o >> .2 S'S Ph No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue ^rect 21 21 21 21 21 21 21 21 21 82 84 05 101 102 104 105 106 107 415 Lacordaire.Lacordaire.Lacord ire Lacordaire.Lacordaire.Lacordaire.Lacordaire .Lacordaire.Lacordaire.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Marie Aida Garneau, epousei de\u2014wife of J.B.D.Lé*aré Prosper Di n et\u2014and Ludger Legault.Marie Aida Garneau, épouse de\u2014wife of J.B.D.Légaré, Prosper Dion et\u2014and Ludger Legault.Rebecca Brûlé, épouse de\u2014 wife of Albert Morissette.Marie Aida Garneau, épouse de\u2014wife of J.B.D.Légaré, Louis Prosper Dion et-and Ludger Legault.Mari Aid i Garneau, épouse de\u2014wife of J.B.D.Légaré Louis Prosper Dion et-and Ludger Legault.Marie Aida Garneau, épouse de\u2014;wife of J.B.D.Légaré.Louis Prosper Dion et-and Ludger Legault.Marie Aida Garneau, épouse de-^wife of J.B.D.Légaré.Louis Prosper Dion et-and Ludger Legault.Marie Aida Garneau, épouse de\u2014wife of J.B.D.Légaré, Louis Prosper Dion et-and Ludger Legault.Marie Aida Garneau, éposue de^wife of J.B.D.Légaré.Louis Prosper Dion et-and Ludger Legault.13.32 Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.46.57|Cotisations annueUes et spéciales\u2014 j Annual and special assessments.19.63 Cotisations annuelle \u2014 Annual assessments.43.83 Cotisations annueUes et spéciale \u2014 Annual and special assessments.43.83 43.83 Cotisations annuelles ct spéciale Annual and pecial assés essment .Cotisations annuelles et spéciales Annual and special asses ments.43.83 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 lAnnual and special assessments.43.84 Cotisation'-annueUes et spéciales i Annual and special assessments.43.84 Cotisations annueUes et spéciales\u2014 Annual and soecial assessments.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.s© 00 S a S 3 a o a £ 0 .s 11 II I s s 52 ¦o 3 .2 S 11 «-» 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 28 108 196 208 219 372 439 502 605 639 912 979 1333 1363 1364 1509 1663 267 504 568,570 1068 3696, 3698 Lacordaire Montaabré Lacordaire Lacordaire Lacordaire Louis Veuillot Lacordaire Lacordaire Lacordaire Montsabré Louis Veuillot Montsabré Montsabré Montsabré Montsabré Montsabré Toulouse.Marie Aida Garneau, épouse de\u2014wifs of J.B.D.Légaré, Louis Prosper Dion et-and Ludger Legault.François-X.Girard.Séphora Boyer, épouse de\u2014 wife of Arthur Tisseur.Jos.Arthur Théoret.Damien Gratton.Jean Versailles.Jos.Isidore Lagacé.Francis Hannan.Jos.Ant.H il aire Hébert.Philemon Gagné.James William Altimas.Jos.Antoine Hilaire Hébert.Jos.Antoine Hilaire Hébert.Jos Antoine Hilaire Hébert____ Jos.Antoine Hilaire H bert.os.Antoine Hilaire Hébert.Arthur Tisseur.43.84 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Mercier.Annual and special assessments.13.25 Cotisations annuelles\u2014 Mercier.Annual assessments.139.89 Cotisations annuelles et spéciale\u2014 Mercier.Annual and special assessmenta 38.78 Cotisations annuelles\u2014 Mercier.Annual assessments.13.25 Cotisations annuelles\u2014 Mercier.Annua! assessments.16.45 Cotisations annuelles\u2014 Mercier.Annual assessments.32.02 Cotisations sociales\u2014 Mercier.Special assessments.49.17 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Mercier.Annual and special assessments.12.20 Cotisations annuelles\u2014 Mercier.Annual assessments.7.91 Cotisations annuelles\u2014 Mercier.Annual assessments.33.36 Cotisations annuelles\u2014 Mercier.Annual assessments.20.75 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Mercier.Annual and special assessments.20.75 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Mercier.Annual and special assessments.20.75 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Mercier.Annual and special assessments.21.80 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Mercier.Annual and special assessmenta 19.6!» Coti ai inns annuelles et spéciales\u2014 Mercier.Annual and special assessments.70.93 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Mercier.Annual and special assessments. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street JS*S -A g II 3 S es c il p sg, II II c h a n a ai |ï| 7 c ° 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 326 268 259 354 627 628 629 630 631 828 829 10-56 Les bâtisses érigées sur les lots-The buildings erected on the lots 326 325 389 389 125 323 60 330 620 321 Toulouse.Toulouse.Cadillac.Duquesne.Duquesnc.Duquesne.Duquesne.Duquesne.Cadillac.Cadillac.Hays.Boyce.Quinn.DrBnu'-h'-rville.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fias municipales Names of wards for municipal purposes Marie Trnttier, épouse de\u2014 wife of Samuel Desy.Marie Trottier, Spouse d< \u2014 wife of Samuel Desy.Aimé Chaput.Pierre L.Wilfrid Dupré.Pierre L.Wilfrid Dupré____ Pierre L.Wilfrid Dupré.Pierre L.Wilfrid Dupré.Pierre L.Wilfrid Dupré____ Eugène Godin.Eugène Godin.Georgianna Hétu, épouse de-wife of Narcisse Legault.Wherry Gardens Limitée\u2014 Limited.Jean-Bte Dagenais.William A.MeManus.29.47 C> tisations annueUes et spec ales\u2014 Annual and special assessments.44 54 Cotisations annuelles et spécial Annual a d special assessments 31.22 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.92 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.6.92 C'oti-ations annuell Annual assessments.0.92 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.6.92 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.6,92 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.25.16 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.25.16 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.60.59 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.63.82 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.14.49 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.7.41 Cotisations annuell Annual a- - .'.eut -.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Merci r.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier. a o a» §¦3 |1 «° i 11 Is.-.s 'Il JS o ¦S3 .2 a ' 380 380 389 389 389 393 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 308 331 332 333 730 733 81 94 188 195 196 219 222 223 224 228 227 262 526 569, 571 4291 Do B ouchervillc.Do Boucher ville.DeBoucherville.Boyce.Boyce.Notre-Dame Est-East.Tellier.Baldwin.Baldwin.\".Ba dwin.Baldwin.Baldw n.Honneur.Honneur.Hon fleur.Honneur.Honneur.Baldwin.William A.McManus.William A.McManus.William A.McManus.Fitz James E.Brown.Fits James E.Brown.Succ.-E8tate James Morley.Albert Zenon Libersan.Alphons9 Fortier.Henri Desfos és.Lachute Land Coy, Incorporée.Lachute Land Coy, Incorporée.Arthur Vaillancourt.Lachute Land Coy, Incorporée.Lachute Land Coy, Incorporée.Lachute Land Coy, Incorporée.Alexandre Wataon.Alexandre Wataon.Agnès Langlois.6.38 6.38 6.38 5.32 6.38 243.27 153.45 24.42 52.67 24.42 24.42 65.62 64.30 23.041 23.04 11.84 41.52 45.29 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessmenta.Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special asse sments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciale \u2014 Special assessments.Cotisa ions annuelles et special Annual and special assessment\".Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spec ales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spécial Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014SuiU Node la eédule Schedule No.Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de ls rua Street number Rue Street is II ii F il *_ .m in fi 308 308 308 308 390 399 399 399 399 399 399 399 399 399 345 631 532 633 59 75 76 86 87 88 142 143 204 282 298, 300.304, 306 4410 Marseilles.De Gros' ois De Gros bois De Groebois Des Ormeaux De Buisson.Des Ormeaux Des Ormeaux Azilda .Azilda.Asilda.A ilda.Azilda.Tellier.Boyce.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014C ntinued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Agnès Allard.Charles Morgan.Charles Morgan.Charles Morgan.Gaspard Dubois.DerviniBea iregard.Dervini Beauregard.Edward Francis Pratt.Edward Francis Pratt.Edward Francis Pratt.J.E.Oswald Chaput.J.E.Oswald Chaput.lean Versailles.Wenceslas Paquette .1 10 10 17 73 1\" 16 37 37 37 36 36 143 118 Cotisations spec ales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuell Annual assessment-.Cotisationsannuel es\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelle \u2014 Annual as-essments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciale î\u2014 Special assessments.Cotisations annueUes et spéciale \u2014 Annual and special assessmenta Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special a -sessments.Cotisations annuelles et née a] Annual and special as essments.Cotisations annuelles et pécial Annual and special assessments.Cotis tions annuel es et spéciales\u2014 Annua and special a sessments.Cotisations annuel es et spéciales\u2014 Annual nd speci 1 assessments.Cotisations spécia e \u2014 .-pecial as-essments.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier. go « >.5 5 il o a Ph « 2* «Ph || -\u2022s 300 397 356 367 376 546 690 755 756 1013 1047 120 210 299 300 304 329 421 595, 597 Langemark Des Ormeaux Des Ormeaux Asilda.DeTeck.Des Ormeaux Asilda.Azilda.Tiffin.Forbin Janson Du buisson .Mousseau.Mousseau.Mousseau.Mousseau.De Teck Mousseau.Jean Versaille Stanislas Monast.Stanislas Monast.Pierre Tétrault.Ladislas Dion Léa Séguin, épouse de\u2014wife of A.Gravel.Pierïe Tétrault.Pierre Tétrault.Hector Hand.Joséphine Séguin, épouse de-wife of Rodrigue Vali-que te.J.E.Oswald Chaput.Winceslas Paquette.Damase Legault et\u2014and Ali-da Courcelles, son épou > his wife.Damase Legault et\u2014and Alicia Courcelles, son épouse;\u2014 his wife.Pierre Tétrault.J.E.Oswald Chaput.Kneen Realties Limitée\u2014 Limited.26.36 Cotisations annuelles c t pédales\u2014 Annual and special asses ments.47.40 Cotisations annuelles et spécial' Annual and special assessmens.47.40 Cotisations annuell.s et spécial ; Annual and special assessments.64.15 Cotisations annuel' Annual assessments.118.45 Cot isation spéciale \u2014 Special assessment-*.32.90 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.20.40 Cotisations spécial(-s\u2014 Special assessments.30.02 Cotisations annuelles et spéciale Annual and special ass ssments.53.82 Cotisa ions nnuel'es et péciales Annual and special assessmen s.!»5.90 Coti-atione annuelles et spéciales Annual and sp.cial a sessments.15.97 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.20.88 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.28.88 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.28.88 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.28.88 Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.45.46 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments 20.88 Cotisations spéciales\u2014¦.Special assessments.Mercier.Mercier.Merc er.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.M rcier.Mercier.Mercer.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.399 399 399 399 399 399 399 399 399 400 400 400 400 400 400 400. f AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street m* -A S g.S 11 il Û Ph _ J5~ ill 511 \u2022o o te 400 400 400 400 400 400 400 406 407 407 408 408 408 422 423 Partie de\u2014part of 698 600 725 1096 1097 Partie de\u2014part of 7 31 143 125 126 Partie de\u2014part of 321 4345 Mousseau.Mousseau.Bellerive.Bellerive.Tellier.Mousseau.Mousseau.Meese.Notre-Dame est\u2014east.Blvd Bilodeau.Contrecœur.Contrecœur.Hector.NOTICE OF SALE OP IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Natuie of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes Kneen Realties Limitée\u2014 Limited.Kneen Realties Limitée\u2014 Limited.Theodore Paquin.Theodore Paquin.Pierre Tétrault.Pierre Tétrault.Pierre Tétrault.Jean Versailles.Oswald Chaput.Basile Faut eux.Alfred Hétu, Joseph Provost et\u2014and Délie Edwidge Sénécal.Alfred Hétu, Joseph Provost et\u2014and Delle Edwidge Sénécal.Alfred Hétu, Joseph Provost et\u2014and Delle Edwidge Sénécal.20.88 19.22 45.43 49.74 14.14 20.89 20.89 11.70 32.95 9.75 20.82 20.82 21.52 Cotisations spécial Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spécial' Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier.Mercier. \u2014 j.« a C H ^ fateBI II -i 8 S a .a a es § 5> a \u202235 go a 3° .8 * O-S-3 «Il eft sa'3 2 5tj5 408 408 409 172 172 172 173 172 172 172 172 172 172 172 172 172 Partie de\u2014part of 322 Partie de\u2014part of 323 393 41 493 534 705 746 803 840 841 842 846 906 907 912 371, 373 et-and 376 365, 367, 360 et-and 369a 1870,1872 381, 381a, 381b Hector.Hector.De Teck.Paul Krvigor.\u20144th Avenue.Maason.7e\u20147th Avenue Masson.9e\u20149th Avenue.9e\u20149th Avenue.9e\u20149th Avenue.9e\u20149th Avenue.9e\u20149tb Avenue 10e\u201410th Avenue 10e 10th Avenue 10e\u201410th Avenue Alfred Hétu, Joseph Provost et\u2014and Delle Edwidge Sénécal.Alfred H, tiu, Joseph Provost, et\u2014and Delle Edwidge Sénécal.Joseph Landry.Adolphe Crète.William Boivin.Rapahel Dufresne.Ernest Joly.Siona Gravel, épouse de-wife of Aldéric Lavergne.Léandre Dubuc.Léandre Dubuc.Léandre Dubuc.Léandre Dubuc.Ferdinand Larose.Armand Vinet.Armand Vinet.Léandre Dubuc.21.52 21.52 G.38 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.63.15 77.40 21.98 76.88 221.79 52.92 52.89 52.89 52.89 116.80 36.72 36.72 36.54 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Spécial assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Animai and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annuai and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Mercier.Mercier.Mercier.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Ho helaga.Hochelaga.c© Cn AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suits Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street a .\u202222 S3 3 g a g 2% a es II î| \u2022al la fi ««.7 o \u2022a \" ¦si c O 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 913 921 981 1090 1091 1134 1335 1336 1517 1518 1519 1550 1551 10e\u201410th Avenue.2050 483 1591,1593 Dandurand.10e\u201410th Avenue.Dandurand.7e\u20147tb Avenue.7e\u20147th Avenue.7e\u20147th Avenue.4e\u20144th Avenue.4e\u2014ith Avenue.Masson.Masson.Masson.Dandurand.Dandurand.NOTICE OF SALE OF IMMOVEABLES\u2014Continued Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour 6ns municipales Names of wards for municipal purposes Léandre Dubuc.| Oscar F.Berthiaume.Adrien Desjardins.Joseph Burelle.Joseph Burelle.Téle8phore Aubut.Siona Gravel, épouse de\u2014wife of Aldéric Lavergne.Siona Gravel, épouse de of Aldéric Lavergne.-wife Albert Levesque.J.-Henri Therrien.J.-Henri Therrien.John Se wick, Pellagia Sewick, épouse de\u2014wife of Brenis-law Janizezah, Salomon Sewick, Edouard Sewick et\u2014 and Raymond Sewick.John Sewick, Pellagia Sewick, épouse de\u2014wife of Brenis-law Janizezah, Salomon Sewick, Edward Sewick ot\u2014 and Raymond Sewick.36.54 151.61 137.29 14.33 14.33 16.96 33.35 33.35 164.08 54.29 54.29 113.70 23.65 Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual asseasments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuell Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.(Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga. 7407 7410 7417 7423 7424 7426 7426 7427 7440 7461 7509 7510 7599 7019 7628 7635 7636 .637 ¦a S \"3 JS -efl 4!- 1 S §2 * o C o II H .2 2 «T3 ¦2 fi 1 g il U o a ¦S3 \u2022| Ci T.fi ¦§8 172 172 172 172 172 172 172 172 183 183 183 183 192 192 192 200 200 200 1796 1995 1996 2101 2102 2103 2208 2209 7,8 21 886 887 1108 1193 1339 25 86 8' 605, 605a, 607, 507a, 509 et \u2014and 511 613, 515, 517,519,519a et-and 621 2008 2048 2701 5e\u20146th Avenue.9e\u20149th Avenue.9e\u20149th Avenue.lOème\u201410th Avenue.lOème\u201410th Avenue.lOème\u201410th Avenue.Holt Avenue.Holt Avenue.Bourbonnière.Bourbonnière.Charlemage.Charlemagne.St-Zotique.Letourneux.Bélanger.Angus Avenue.Angus Avenue.Angus Avenue.Léandre Dubuc.Alcide Rivest.Alcide Ri vest.Armand Vinet.Armand Vinet.Armand Vinet.Aimé Handfield.Aimé Handfield.Louis Brosseau.Arthur Lussier.William Everall.William Everall.Joseph Fleury.Marcelin Fabre.Arthur Bousquet.C.E.Lamoureux.C.E.Lamoureux.C.E.Lamoureux.37.125 125 32 32 32 150 36 53 42.34 34.8 17 30 10 9, 9.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations spéciales\u2014 Special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles et spécial Annual and special assessments Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations nanuell Annual assessments.Cotisations annuelles et spéciales\u2014 Annual and special assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annueUes\u2014 Annual assessments.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hcchelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga. AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES\u2014Suite NOTICE OF SALE OF IM MOVEABLES\u2014Continued Quartier Ward No du cadastre Cadastral No.Subdivision No de la rue Street number Rue Street Propriétaire cotisé Assessed proprietor Montant Amount claimed Nature des réclamations Nature of claims Noms des quartiers pour fins municipales Names of wards for municipal purposes l So,-a g lilts Ha§sl 3 b.S S a 73 \u2022§ '3 g °Z Ph 200 206 207 207 207 314 207 208 897 830, 832 et\u2014and 834 -Angus Avenue.Harold.Molson.Molson.Blvd Rosemont.C.E.Lamoureux.Wilson Ayotte.Joseph Philippe Arthur Bélanger.Joseph Philippe Arthur Bélanger.Aimé Handheld.9.59 46.82 8.77 8.77 29.33 Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuciles\u2014 Annual assessments.Cotisations annuelles\u2014 Annual assessments.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Hochelaga.Pour être vendues à mon bureau, dans la cité de Montréal, LUNDI, le QUINZIEME jour d'OCTOBRE prochain, à DIX heures de l'avant-midi.Un dépôt sera exigé du plus haut enchérisseur, avant l'adjudication finale, suivant le paragraphe 401, chapitre 58, 62 Victoria, P.Q.L.-J.LEMIEUX, Bureau du shérif.Shérif.Montréal, 29 août 1917.3961 To be sold at my office, in the city of Montreal, on MONDAY, the FIFTEENTH day of OCTOBER next, at TEN o'clock in the forenoon.A deposit shall be exacted from the highest bidder before final adjudication, according to the paragraph 401, chapter 58, 62 Victoria, P.Q.L.-J.LEMIEUX, Sheriff's office, Sheriff.Montreal, 29th August, 1917.3962 CO Or I 2059 VENTES PAR LES SHÉRIFS BEDFORD SHERIFFS' SALES BEDFORD AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES et HERITAGES sous mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs tel que mentionné plus bas.Cour supérieure.\u2014District de Bedford.Province de Québec, ) D OMULUS CLOU-District de Bedford, | *\\ TIER, deman-No9881.' deur ; contre les meubles et effets, les terres et héritages de JOSEPH L APRÈS, défendeur.Saisis comme appartenant audit défendeur : 1.Le lopin de terre situé dans le canton Ely, dans le district de Bedford, et présentement connu sur les plan et livre de renvoi dudit canton Ely, comme étant un arpent.plus ou moins, du lot numéro quatre-vingt-sept (87), à distraire de la partie nord dudit lot et comprenant tout le terrain inclus dans une courbe décrite par le ruisseau qui traverse ledit lot, tel qu'acquis par acte de vente et transport de Moïse Laprô, devant P.-J.-S.Peltier, sous le numéro 53808, Reg.\" B \", Vol.81\u2014avec toutes les améliorations qui s'y trouvent.1.\"A\".Partie du lot numéro quatre-vingt-huit (88), des plan et livre de renvoi du cadastre dudit canton Ely, à distraire de la partie sud dudit lot à l'ouest du chemin qui traverse ledit lot et le divise dans sa longueur en environ douze portions égales, ladite partie de terrain mesurant huit perches en longueur à l'est le long du chemin publient neuf perches à l'ouest le long du ruisseau; bornée au sud par le lot du cadastre No 87, mesurant environ deux arpents\u2014avec toutes les améliorations, un moulin à scie et d'autres structures construites sur les deux dits lots sus-décrits.y compris toutes machines y contenues et fixées à demeure, aussi la force hydraulique et le barrage du ruisseau appuyés sur chaque côté dudit ruisseau et ces parties desdits lots numéros 87 et 88 ; 2.La ferme située dans le canton Ely, dans le district de Bedtord, et actuellement connue aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton Ely, comme étant le quart nord du lot numéro cent soixante-cinq (165) ; la moitié nord du lot numéro cent soixante-six (166) ; et les lots numéros cent soixante-sept (167) ; cent soixante-neuf (169) ; cent soixante^Ux (170) ; la partie est du lot numéro cent soixante-douze (172) ; et le lot numéro cent soixante-treize (173), mesurant en tout quatre cent6 acres de terre en étendue, plus ou moins\u2014avec toutes les améliorations qui s'y trouvent.Suivant jugement de la cour supérieure, en date du 26 juillet 1917, la propriété immobilière plus haut décrite sera vendue en bloc, comme un tout, à la porte de l'église de la paroisse de Saint-Théophile-d'Ely, à Racine (ainsi nommé), dans le canton Ely, dit district, le QUINZIEME jour de SEPTEMBRE prochain 1917, à UNE heure de l'après-midi.Le shérif, C.-B.JAMESON.Bureau du shérif.Sweetsburg, Que., 30 juillet 1917.3595\u201431-2 [La première publication du 4 août 1917 est nulle].[Première publication, 11 août 1917].PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, ami will be sold at the respective times and places mentioned below.Superior Court.\u2014District of Bedford.Province of Quebec, ) ROMULUS CLOU-District of Bedford, - i\\ TIER, plaintiff ; No.9881.' against the goods and chattels, lands and tenements of JOSEPH LAPRÉS, defendant.Taken in execution as belonging to the said defendant : 1.That certain piece of land situated in the township of Ely, in the district of Bedford, and now known on the official plan and in the book of reference of the said township of Ely, as one arpent, more or less, of lot number eighty seven (87).to be detached from the north part of said lot and including all the land comprised in a curve formed by the brook crossing said lot, as acquired by deed of sale and conveyance from one Moïse Lapré, before P.-J.-S.Peltier, under number 53808, Reg.\" B \", Vol.81\u2014with all improvements thereon.1.\"A\".Part and parcel of lot number eighty eight (88), of the cadastral plan and book of reference of the said township of Ely, to be detached from the south part of said lot, on the west side of the road crossing said lot and dividing it on its length in about twelve equal halves, said part or parcel of land being eight perches in length on the east line along the public road, and nine perches on the west line along the brook, and bounded south by cadastral lot No.87, measuring about two arpents\u2014with all improvements thereon, together with a saw mill and other buildings erected and made on the said above described two lots, including all machinery therein contained and fixed permanently, and also the water-power and dam across the brook resting on each side of said brook on those parts of said lots numbers 87 and 88 ; 2.That certain farm situated in the township of Ely, in the district of Bedford, and now known on the official plan and in the book of reference of the said townsliip of Ely, as the north quarter of the lot number one hundred and sixty five, (165) ; the north half of lot number one hundred and sixty six (166) ; and lots numbers one hundred and sixty seven, (167) ; one hundred and sixty nine, (169) ; one hundred and seventy, (170) ; the east part of lot number one hundred and seventy two, (172) ; and lot number one hundred and seventy three.(173), containing in all four hundred acres of land in superficies, more or less\u2014 with all improvements thereon erected and made.Pursuant to a judgment of the Superior Court, dated the 26th July, 1917, the foregoing described immoveable property will be sold \" en bloc \", together as a whole, at the parochial church door of the parish of Samt^Théophile-d'Ely, at Racine (so called), in the township of Ely, said district, on the FIFTEENTH day of SEPTEMBER next, 1917, at the hour of ONE of the clock in the afternoon.C.-B.JAMESON, Sheriff.Sheriff's office.Sweetsburg, Que., 30th July, 1917.3596\u201431-2 [First publication of 4th August, 1917 is null.] [First publication, 11th August, 1917]. 2060 JOLIETTE JULIETTE FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Cour supérieure.\u2014District de Jolielte.Province de Québec,) ARTHUR THE- No 3959.] *» RIAULT, deman-Joliette.à savoir: > deur; vs EVAN- GELISTE L'EPICIER, défendeur.a.Un terrain connu et désigné sous le No 40, dans le 1er rang du canton Joliette; b.Un terrain connu et désigné sous le No 30, dans le 1er rang du canton Joliette, avec tous les fils, poteaux et autres accessoires servant à l'exploitation d'une usine construite sur cet inuneuble pour la production et transmission de l'électricité, ainsi que tous les droits et privilèges résultant au défendeur d'un règlement adopté par le conseil municipal de la paroisse de Sainte-Emélie de l'Energie, connu comme étant le règlement No 19, et accordant au défendeur pour vingt-cinq aimées consécutives, un privilège exclusif pour pourvoir à l'éclairage d'une partie du territoire de ladite paroisse de Sainte-EméUe-de-l'Energie.Pour être vendus à la porte de l'église de la paroisse de Sainte-Emélie-de-1'Energie, MARDI, le DIX-HUIT SEPTEMBRE mil neuf cent dix-sept, à UNE heure de l'après-midi.Le shérif, JOSEPH GADOURY Bureau du shérif.Joliette.15 août 1917.4015\u201435-2 Première publication, lei septembre 1917].MONTRÉAL FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Circuit Court.\u2014District of Joliette.Province of Quebec,) ARTHUR THE-No.3959.[ r% RIAULT plain-Joliette, to wit: t tiff; vs EVANGELISTE L'EPICIER, defendant.a.That certain lot oi land known and designated under the No.40, in the first range of Joliette township; b.That other lot of land known and designated under No.30, in the first range of Joliette town-sbjp, with all the wires, poles and other accessories used in the operation of a shop erected upon transmission of electricity, together with all the rights and privileges granted to the defendant under a by-law adopted by the municipal council of the parish of Sainte Emelie-de-l'Energie, known as by-law No.19, and granting the defendant for twenty five consecutive years, the exclusive privilege to supply lighting for a certain part of the territory of said parish of Saintc-Emelie-de-l'Energie.To be sold at the church door of the parish of Sainte-Emelie-de-l'Energie, on TUESDAY, the EIGHTEENTH day of SEPTEMBER, one thousand nine hundred and seventeen, at ONE o'clock in the afternoon.JOSEPH GADOURY, Sheriff.Sheriff's office.Joliette, 15th August, 1917.4016\u201435-2 [First publication, 1st September, 1917].MONTREAL FIERI FACIAS DE TERRIS Cour supérieure.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir :\\F\\AME ROSE deLIMA No 3541./JL^ LAMARRE, épouse séparée de biens par contrat de mariage de Pierre Noël, tant personnellement qn'ès-qualitf et ledit Pierre Noël pour autoriser son épouse aux présentes, demanderesse ; vs FRANÇOIS-XAVIER LEBLANC, es-qualité, défendeur; et TELES-PHORE DESPATIE, curateur au délaissement.L'immeuble décrit comme suit, savoir : Deux lots de terre situés en la cité de Montréal, connus et désignés sous les numéros 59 et 60 de la subdivision officielle du lot numéro 10 (10-59 et 60), sur les plan et livre de renvoi officiels du village incorporé de Saint-Jean-Baptiste, dans le comté d'Hochelaga\u2014avec les bâtisses et autres dépendances dessus construites et portant les numéros civiques 474 à 480 de la rue Mentana, et 510 à 516 de la rue Marie-Anne Est.Pour être vendus à mon bureau, en la cité de Montréal, le TREIZIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à TROIS heures de l'après-midi.Le shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 8 août 1917.3735\u201432-2 [Première publication, 11 août 1917.] FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Cour supérieure.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir:\\ A LPHONSE POIRIER, No 2637./ *» demandeur; vs EPHREM-G.HURTUBISE, défendeur.FIERI FACIAS DE TERRIS Superior Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit:\\ rvAME ROSE deLIMA No.3541./ LAMARRE, wife separated as to property by marriage contract of Pierre Noël, both personally and es-qualité, and the said Pierre Noël to authorize his wife for the purposes hereof, plaintiff ; vs FRANÇOIS-XAVIER LEBLANC, es-qdalité, defendant; and TELESPHORE DEPATIE, curator to the surrender of property made herein.The immoveable described as foUows, to wit: These two lots of land situated in the city of Montreal, known and designated under the numbers 59 and 60 of the official subdivision of the lot number 10 (10-59 and 60), on the official plan and book of reference of the incorporated village of Saint-Jean-Baptiste, in the county of Hochelaga\u2014with the buildings and other dependencies thereon erected and bearing civic numbers 474 to 480 in Mentana street, and 510 to 516 in Marie-Anne street East.To be sold at my office, in the city of Montreal, on the THIRTEENTH day of SEPTEMBER next, at THREE o'clock in the afternoon.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office.Montreal, 8th August, 1917.3736\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917.] FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Superior court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit:\\ A LPHONSE POIRIER, No.2637./ ^plaintiff; vsEPHREM-G.HURTUBISE, Defendant. 2061 Le lot de terre connu et désigné comme étant le lot No 55, sur les plan et livre de renvoi officiels du village du canton de Chambly, dans le comté de Chambly, ayant front sur la rue Bourgogne\u2014 avec les bâtisses dessus érigées.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de Chambly canton, le QUATORZIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à ONZE heures de l'avant-midi.Le shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 8 août 1917.3737\u201432-2 [Première publication, 11 août 1917].That certain lot of land known and designated as being the lot No.55, upon the official plan and book of reference of the village of Canton de Chambly, in the county of Chambly, fronting on Bourgogne street\u2014with the buildings thereon erected.To be sold at the parocliial church door of the parish of Chumblv Canton, on the FOURTEENTH day of SEPTEMBER next, at ELEVEN o'clock in the forenoon.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office.Montreal, 8th August, 1917.3738\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917].FIERI FACIAS DE TERRIS Cour supérieure.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir: \\ pEORGES KYDD, No 2797./ demandeur ; vs HARRY alias HARRY-J.HOPE, défendeur.Certains lots de terre situés dans la cité de Montréal, ayant front sur la rue de Saint-Réal, connus et désignés sous les numéros trois et quatre de la subdivision cent trente-neuf, et deux de la subdivision cent quarante de la subdivision officielle du lot deux cent quatre-vingt-onze (291-139-3, 139-4 et 140-2), des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse du Sault-au-Récollet, tel que le tout se trouve présentement\u2014avec toutes les servitudes passives et actives, apparentes ou occultes attachées auxdits immeubles.Pour être vendus à mon bureau, en la cité de Montréal, le TREIZIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à DEUX heures de l'après-midi.Le shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 8 août 1917.3739\u201432-2 [Première publication, 11 août 1917.] FIERI FACIAS DE TERRIS Superior Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit: I (~* EORGES KYDD, plain-No.2797.I VJ tiff ; vs HARRY alias HARRY-J.-HOPE, defendant.Certain lots of land situate in the city of Montreal, fronting on Saint Real street, known and designated under the numliers tliree and four of the subdivision one hundred and tlùrty nine, and two of the subdivision one hundred and forty of the official subdivision of the lot two hundred and ninety one (291-139-3, 139-4 and 140-2), on the official plan and book of reference of the parish of Sault-au-Récollet, as the whole presently is\u2014with all the active and passive servitudes, apparent or occult attached to the said immoveables.To be sold at mv office, in the city of Montreal, on the THIRTEENTH day of SEPTEMBER next, at TWO o'clock in the afternoon.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office.Montreal, 8th August, 1917.3740\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917.] FIERI FACIAS DE TERRIS.Cour supérieure.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir :\\ A LEXANDRE MO-No262.j « QUIN, demandeur ; vs DAME MARIE-LOUISE ANGRI-GNON, épouse séparée de biens de Ferdinand Lespérance, et faisant affaires sous les nom et raison sociale de \" Montreal Property Company \", et ce dernier pour autoriser son épouse aux' fins des présentes ; et TELESPHORE DEROME, curateur au délaissement.Un emplacement ayant front sur la rue Saint-Iaurent, en la cité de Montréal, et composé comme suit : 1.Le lot No 1 de la resubdivision du lot No 242 du lot originaire No 11, aux plan et livre de renvoi officiels du village incorporé de la Côte -Saint-Louis ; 2.Du lot No 2 de la resubdivision du lot No 241 du lot originaire No 11, aux plan et livre de renvoi officiels du village incorporé de la Côte-Saint-Louis\u2014et les bâtisses sus-érigées.Pour être vendu à mon bureau, en la cité de Montréal, le TREIZIEME jour de SEPTEM-BREjDrochain, à ONZE heures du matin.Le shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 8 août 1917.3741\u201432-2 [Première publication, 11 août 1917.] FIERI FACIAS DE TERRIS.Superior Court.\u2014District of Montréal.Montreal, to wit : 1 A LEXANDRE MO-No.262.i r\\ QUIN, plaintiff; vs DAME MARIÉ-LOUISE ANGRIGNON, wife separated as to property of Ferdinand Iiespéranee, and carrying on business under the firm, name and style of \" Montreal Property Company \", and the latter to authorize his wife for the purposes hereof ; and TELESPHORE DEROME, curator to the surrender.An emplacement fronting on Saint-lAwrence street, in the city of Montreal, and composed as follows : 1.Lot No.1 of the resubdivision of the lot No.242 ot the primitive lot No.11, on the, official plan and book of reference ot the incorporated village ol Côte-Saint-Ix)uis ; 2.I/Ot No.2 ot the resubdivision ot the lot No.241 of the primitive lot No.11.on the official plan and book of reference of the incorporated village of Côte-Saint-Louis\u2014and the buildings erected thereon To be sold at my office, in the city of Montreal, on the THIRTEENTH day of SEPTEMBER next, at ELEVEN o'clock in the forenoon.L.-J.LEMIEUX.Sheriff.Sheriff's office.Montreal, 8th August.1917.3742\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917.] 2062 FIERI FACIAS DE TERRIS.Cour supérieure.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir:\\ DASCAL GAGNON, de-No 2979.J * mandeur; vs ARTHUR LACOSTE, BERNARD DAMIENS & JOSEPH-HORACE DAVID, défendeurs; et F.-R.VINET & P.-H.DUFRESNE \"Vinet & Dufresne\", de Montréal, curateurs au délaissement.Immeuble saisi (ci-devant appartenant aux défendeurs) et présentement en la possession des curateurs au délaissement.Un lot de terre sis et situé en la cité d'Outre-mont, district de Montréal, ayant front sur l'avenue McDougall, de ladite cité, connu et désigné comme étant le lot numéro cinq cent cinquante-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro trente-cinq (35-556), des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Montréal, sans bâtisse.Pour être vendu à mon bureau, en la cité de Montréal, le TREIZIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à DIX heures du matin.Ijg shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 8 août 1917.3743\u201432-2 [Première publication, 11 août 1917].FIERI FACIAS DE TERRIS.Superior court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit:\\ DASCAL GAGNON.No.2979.I » Plaintiff; vs ARTHUR LACOSTE, BERNARD DAMIENS and JOSEPH-HORACE DAVID, Defendants et F.-R.VINET & P.-H.DUFRESNE \"Vinet à Dufresne\", of Montreal, curators to the surrender.The immoveable seized (heretofore belonging to the defendants) and presently in tlie possession of the curators to the surrender.A lot of land being and situate in the city of Outremont, district of Montreal, fronting on McDougall Avenue, of the said city, known and designated as being the lot Dumber five hundred and fifty six ot the official subdivision of the primitive lot number thirty five (35-556), on the official plan and book of reference oi the parish of Montreal\u2014without building.To l>e sold at my office, in the city of Montreal, on the THIRTEENTH day of SEPTEMBER next, at TEN o'clock in the forenoon.L.-J.LEMIEUX, Sheriff, Sheriff's office.Montreal, 8th August, 1917.3744\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917].FIERI FACIAS DE TERRIS.Cour de circuit.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir :\\ T Z.GAGNIER, deman-No 21014.J J \u2022 deur ; vs E.-R.DUFRESNE, défendeur.Six lots connus et désignés comme étant les subdivisions 199, 200, 201, 202, 203, 204 du lot No 97, aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse du Sault-au-Récollet; lesdits lots' ayant front sur la rue Ottawa, dans le parc Ottawa, dans la ville de Montréal-Nord.Pour être vendus à mon bureau, en la cité de Montréal, le TREIZIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à MIDI.Le shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 8 août 1917.3745\u201432-2 [Première publication, 11 août 1917.] FIERI FACIAS DE TERRIS.Circuit Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit :\\ ï Z.GAGNIER, plaintiff; No.21014./ J \u2022 vs E.-R.DUFRESNE, defendant.Those six lots of land known and designated as being the subdivisions 199, 200, 201, 202, 203, 204 of the lot No.97, on the official plan and book of reference of the parish of Sault-au-Récollet; the aforesaid lots fronting on Ottawa street, in Ottawa Park, in the town of Montreal North.To be sold at my office, in the city of Montreal, on the THIRTEENTH day of SEPTEMBER next, at TWELVE o'clock NOON.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office.Montreal, 8th August, 1917.3746\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917.] FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS Cowr supérieure.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir :\\nAME MARIE-LOUISE No 36.) LJ SENECAL, veuve de feu Edouard Lapare, demanderesse ; vs DAME MARY-ANN McGOLDRICK, veuve de feu James-J.Kavanagh et Michael-P.McGoldrick, en leur qualité d'exécuteurs-testamentaires de la succession de feu Patrick-T.McGoldrick, défendeurs.Un lot de terre situé dans le quartier Saint-Henri, dans la cité de Montréal, sur les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine, connu comme étant le No 1637, aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Montréal, à déduire cependant dudit lot les parties expropriées par l'ancienne ville de Saint-Henri\u2014avec bâtisses dessus érigées.Pour être vendu à mon bureau, en la cité de Montréal, le QUATORZIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à DIX heures du matin.Le shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 8 août 1917.3747\u201432-2 [Première publication, 11 août 1917.] FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Superior Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit :\\ r\\AME MARIE-LOUISE No.36./ LS SENECAL, widow of the late Edouard Lapare, plaintiff; vs DAME MARY-ANN McGOLDRICK, widow of the late James-J.Kavanagh and Michael-P.McGoldrick, in their quality of testamentary executors to the estate of the late Patrick-T.McGoldrick, defendants.That certain lot of land situated in Saint Henri ward, in the city of Montreal, on Saint James and Saint Antoine streets, known as being the No.1637, on the official plan and book of reference of the parish of Montreal, save and except therefrom however the parts thereof expropriated by the former town of Saint Henri\u2014with the buildings thereon erected.To be sold at my office, in the city of Montreal, on the FOURTEENTH dfry of SEPTEMBER next, at TEN o'clock in the forenoon.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office, Montreal, 8th August, 1917.3748\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917].? 2063 FIERI FACIAS DE TERRIS Coter de circuit.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir: W A CITE DE LACHI-No 3099./ NE, (H>rps politique et incorporé,ayant son bureau d'affaires dans la cité de Iachine, district de Montréal, denianderesse ; vs WIARTON REALTY COMPANY, LIMITED, compagnie constituée en corporation par lettres patentes de la Puissance du Canada, et ayant son bureau d'affaires dans la cité de Wiarton, province d'Ontario, défenderesse.Les lots de terre Nos 4, 5.6, 7.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.19, 20.21, 22.23.24, 26, 26, 27, 28, de la subdivision officielle du lot No 809, des plan et livre de renvoi de la paroisse de Iachine, dans le comté de Jacques-Cartier ; la partie du lot de terre No 20 de la subdivision officielle du dit lot No 899.mesurant dans sa ligne nord 80.1 pieds; dans sa ligne nord-est 35.6 pieds ; dans sa ligne est 36.4 pieds ; dans sa ligne sud 113 pieds ; dans sa ligne ouest 50 pieds, formant une sutK'rficie d'environ 5247 pieds, et bornée au nord par le lot de terre No 30 de la subdivision officielle dudit lot No 899, au nord-est par la partie dudit lot No 29, appartenant à la Montreal Tramways Company ou représentants ; a Test par les lots de terre Nos 32 et 33.des plan et livre de renvoi de la ville de Lachine, au sud par le lot de terre No 28 «le la subdivision officielle du dit lot No 899, et à l'ouest par le lot de terre No 62 de la subdivision officielle dudit lot No 899 ; et la partie en forme triangulaire du lot de terre No 30, de la subdivision officielle dudit lot No 899, mesurant dans sa ligne nord-est 86.97 pieds, dans sa ligne sud 80.1 pieds,dans sa ligne ouest 33.9 pieds, contenant une superficie d'environ 1358 pieds, et bornée au nord-est par la partie dudit lot No 30, appartenant à la Montreal Tramways Company, ou représentants, au sud par le lot de terre No 29 de la subdivision officielle dudit lot No 899, à l'ouest par le lot de terre No 62 de la subdivision officielle dudit lot No 899 ; le tout mesure anglaise.Tous ces lots et parties de lots ont front sur le côté est du lot de terre No 62, de la subdivision officielle dudit lot No 899, désigné et destiné à servir de rue et passage desservant les lots de subdivision dudit lot No 899, ayant front sur ce lot No 62, suivant plan de subdivision dudit lot No 899, et livre de renvoi officiels déposés au bureau du commissaire des terres de la Couronne et au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement des comtés d'Hochelaga et Jacques-Cartier, en décembre 1901.La partie du lot de terre No 33 de la subdivision officielle dudit lot No 899, mesurant dans sa ligne nord-est 122.5 pieds ; dans sa ligne est 11.6 pieds ; dans sa ligne sud 113 pieds, dans sa ligne ouest 58.9 pieds, contenant en superficie environ 3984 pieds, le tout mesure anglaise, et bornée au nord-est par la partie du même lot, de la subdivision appartenant à la Montreal Tramways Company ou représentants, M'est par le lot No 62 de la subdivision officielle dudit lot No 899, au sud par le lot No 34 de la subdivision officielle dudit lot No 899, à l'ouest par les lots Nos 89 et 90, de la subdivision officielle dudit lot No 899 ; et les lots de terre Nos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59 de la subdivision officielle dudit lot No 899.Tous ces lots et parties de lots ont front sur le côté ouest du lot de terre No 62 de la subdivision officielle dudit lot No 899, désignés et destinés à servir de rue et passage desservant les FIERI FACIAS DE TERRIS.Circuit Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit :) T7HE CITY OF LACHI-No.3099./ * NE.a body politic and corporate, liaving its head office in the city of Laehine, district of Montreal, plaintiff ; vs WIARTON REALTY COMPANY, LIMITED, a company incorporated by letters patent of the Dominion of Canada, and having its head office in the city of Wiarton, Province of Ontario, defendant.The lots of land Nos.4, 5, 6.7, 8, 9.10.11, 12, 13, 14, 15, 16.17, 18, 19, 20, 21.22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 of the official subdivision of the lot No.899, of the official plan and book of reference of the parish of lachine, in the county of Jacques-Cartier : that part of the lot of land No.29 of the official subdivision of said lot No.899, measuring in the northern line 80.1 feet, in its northeastern line 85.0 feet, in its eastern line, 36.4 feet, in its southern line 113, feetand in its western line 50 feet, containing a suj)erficial area of about 5247 feet, and hounded on the north by the lot of land No.30 of the official subdivision ot said lot No.899, on the north east by that part of said lot No.29, belonging to the Montreal Tramways Company or representatives, on the east by the lots of land Nos.:{:.' and 33, of the official plan and book of reference of the town of Lachine, on the south by the lot ot land Xo.28 of the official subdivision of said lot No.899, and on the west by the lot ot land No.62 of the official subdivision of said lot Xo.899; and the triangularly shaped part of the lot of land Xo.30.of the official subdivision of said lot Xo.899, measuring in its northeastern line.86.97 feet, in its southern line 80.1, and in its western Une 33.9 feet, containing a superficial area of about 1358 feet, and bounded on the north east by that part of said lot No.30, belonging to the Montreal Tramways Company, or representatives, on the south by the lot of land Xo.29 of the official subdivision of said lot No.899, on the west by the lot of land No.62 of the official subdivision of said lot No.899, the whole english measure.All the above lots and parts of lots front on the eastern side ot the lot of land Xo.62 of the official subdivision of said lot No.899, designated as and destined for x street and passage for the use of the subdivision lots ot said lot No.899, fronting on said lot No.62, as per the subdivision plan of said l.)t No.899, and the book of reference deposited at the office of the Commissioner of Crown Lands and in Registrar's Office of the registration division of the counties of Hochelaga and Jacques-Cartier, in December, 1901.That part ot the lot of land No.33 of the official subdivision of said lot No.899, measuring in its northeastern line 122.5 feet, in its eastern line 11.6 feet, in its southern line 113 feet, and in its western line 58.9 feet, containing about 3984 feet in superficial area, the whole english measure, and bounded on the north east by that part of same lot, of the subdivision belonging to the Montreal Tramways Company or representatives, on the east by the lot No.62 of the official subdivision of said lot No.899, on the south by the lot No.34 of the official subdivision of said lot No.899, on the west by the lots Nos.89 and 90 of the official subdivision of said lot No.899 ; and the lots of land Nos.34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 and 59 of the official subdivision of said lot No.899.All the above lots and parts of lots fronting on the western side of the lot of land 2064 lots (le subdivision dudit lot No 899, ayant front sur icelui comme susdit.I*s lois de terre Nos 61, 63, 123 et 124 de la subdivision officielle du dit lot No 899 ayant front sur la rue Saint-Joseph\u2014avec bâtisses dessus construites.Ixîs lots de terre Nos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,74, 75, 76, 77, 78, 79.80, 81, 82, 83,84, 85, 86, 87, 88 et 89 de la subdivision officielle du dit lot No899, et la partie du lot de terre No 90, de la subdivision officielle dudit lot No 899, mesurant dans sa ligne nord, 15.6 pieds ; dans sa ligne nord-est 105.71 pieds ; dans sa ligne est 8.9 pieds ; dans sa ligne sud 113 pieds, dans sa ligne ouest 50 pieds, contenant en superficie environ 3648 pieds, le tout mesure anglaise, et bornée au nord par le lot de terre No 91, de la subdivision officielle dudit lot No 899, au nord-est par la partie dudit lot de terre No 90, appartenant à la Montreal Tramways Company ou représentants, à l'est par le lot rïe terre No 33 de la subdivision officielle dudit lot No 899, au sud par le lot de terre No 89, de la subdivision officielle dudit lot No 899.et â l'ouest par le lot de terre No 125.de la subdivision officielle dudit lot No 899.Tous ces lots et parties de lots ont front sur le côté est du lot No 125 de la subdivision officielle dudit lot No 899, désignés et destinés à servir de rue et passage desservant les lots de subdivision dudit lot No 899, ayant front sur ce lot No 125, suivant plan de subdivision dudit lot No 899 et livre de renvoi officiels déposés au bureau du Commissaire des terres de la Couronne et au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement des comtés d'Hochelaga et Jacques-Cartier, en décembre 1901.La partie du lot de terre No 94 de la subdivision officielle dudit lot No 899, de forme irréguliere, mesurant dans sa ligne nord-est environ 87.6 pieds, dans sa ligne sud 81.1 pieds, dans sa ligne ouest 33.4 pieds, contenant une superficie d'environ 1,390 pieds mesure anglaise,et bornée au nord-est par le résidu dudit lot de terre No 94, appartenant à la Montreal Tramways Company ou représentants, lequel est délimité vers le sud-est par mie ligne partant d'un point sur la limite sud dudit lot No 94, â 38.7 pieds de la limite est dudit lot courant parallèlement au lot No 1037, desdits plan et livre de renvoi de la paroisse de Lachine jusqu'à un point 18.5 pieds de la limite ouest du dit lot No 94, et de la suivant une courte à un rayon de 2832 pieds jusqu'à un point de la limite ouest dudit lot No 94 à 33.4 pieds de la limite sud dudit lot 94 ; bornée au sud par le lot de terre 95, de la subdivision officielle dudit lot No 899, à l'ouest par le lot de terre No 898, des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Lacliine; la partie du lot de terre No 95.de la subdivision officielle dudit lot No 899, mesurant dans sa ligne nord 81.1 pieds,dans sa ligne nord-est 41.9 pieds, dans sa ligne est 33.4 pieds, dans sa ligne sud 119 pieds, dans sa ligne ouest 50 pieds, contenant en superficie environ 5646 pieds, le tout mesure anglaise et bornée au nord par le lot de terre No 94, de la subdivision officielle dudit lot No 899, au nord-est par le résidu dudit lot No 95,apparte-nant A la Montreal Tramways Company ou représentants, à l'est par le lot de terre No 125 de la subdivision officielle dudit lot No 899, au sud par le lot de terre No 96, de la subdivision officielle dudit lot No 899, et à l'ouest par ledit lot No 898 et les lots de terre Nos 96, 97, 98, 99.100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 et 122, de la subdivision officielle dudit lot No 899.Tous No.62 of the official subdivision of said lot No.899, designated as and destined for a street or passage tor the use of the subdivision lots of said lot No.899, fronting thereon as aforesaid.The lots of land Nos.61, 63, 123 and 124 of the official subdivision of said lot No.899, fronting on Saint-Joseph street\u2014with the buildings thereon erected.The lots of land Nos.64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.74, 75, 76, 77, 78.79, 80, 81, 82, 83, 84 , 85, 86, 87, 88 and 89 of the official subdivision ot said lot No.899, and that part ot lot No.90, of the official subdivision of said loi No.899, measuring in its northern line.15.6 fee in its north eastern line 105.71 feet, in its eastern line, 8.9 feet, in its southern line 113 feet, and in its western line 50 feet, containing alxmt 3648 feet in superficial area, the whole english measure, and bounded on the north by the lot of land No.91, of the official subdivision ol said lot No.899, on the north east by that part of said lot No.90, belonging to the Montreal Tramway* Company or representatives, on the east by the lot of land No.33 oi the official subdivision of the lot No.899, on the south by the lot ol land No.89, of the official subdivision of said lot No.899, and on the west by the lot ot land No.125, of the official subdivision of said lot Xo.899.AU the above lots and parts ot lots front on the eastern side of the lot Xo.125 of the official subdivision of said lot Xo.899, designated as and destined for a street and passage tor the use of tlie subdivision lots of said lot No.899, fronting on such lot No.125, as per subdivision plan ot said lot Xo.899, deposited in the office of the Commissioner of Crown Lands and in the Registrar's office of the registration division of the counties of Hochelaga and Jacques-Cartier, in I)eceml)er, 1901.That part of the lot oi land No.94 of the official subdivision of said lot No.899.of irregular outline, measuring in its northeastern line about 87.6 feet, in its southern line, 81.1 feet, in its western line, S3.4 feet, containing about 1,390 feet in superficial area, and bounded on the north east by the residue ot said lot of land No.94, belonging to the Montreal Tramways Company or representatives, which is bounded on the south east by a line starting from a point in the southern limit of said lot Xo.94, 38.7 feet distant from the eastern limit ot said lot and running parallelly to the lot Xo.1037, of said plan and book of reference of the parish of Lachine to a point 18.5 feet distant from the western limit of said lot No.94, thence following a curve with a radius ot 2832 feet to a point in the western limit of said lot No.94.33.4 feet distant trom the southern limit of said lot Xo.94 ; bounded on the south by the lot of land No.95 of the official subdivision of said lot Xo.899, on the west by the lot of land No.898, of the official plan and lx)ok of reference of the parish of Lachine, that part of the lot of land No.95, ot the official subdivision of said lot No.899, measuring in its northern line 81.1 feet in its northeastern line, 41.9 feet, in its eastern line 33.4 feet, in its southern line, 119 feet, in its western line 50 feet, and containing about 5646 feet, in superficial area, the whole english measure, and bounded on the north by the lot of land No.94 of the official subdivision ot said lot No.899, on the north east by the residue of said lot No.95, belonging to the Montreal Tramways Company or representatives, on the east by the lot of land No.125 of the official subdivision of said lot No 899, on the south by the lot of land No.96, of the official subdivision of said lot No.899, on the west by said lot No. 2005 ces lots et parties de lots ont front sur le côté ouest du lot No 125, de la subdivision officielle dudit lot No 899, désigné et destiné à servir de rue et passage desservant les lots de sulxlivi-sion dudit lot No 899, ayant front sur ce lot No 125 connue susdit.La partie du lot de terre No 62, de la subdivision officielle dudit lot No 899, mesurant 66 pieds de largeur par environ 1526.5 pieds de longueur, dans ses lignes est et ouest, contenant en luperfioe environ cent trois mille soixante-treize pieds, mesure anglaise ; bornée au nord par le résidu du dit lot No 62, appartenant à la Montreal Tramways Company ou représentants, à l'est par les lots de terre Nos 2,3, 4, 5, 6,7,8, 9.10, 11,12, 13, M, 15.16.17, 18, 19, 20.21.22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, de la subdivision officielle du dit lot No N99.au sud par la rue Saint-Joseph, à l'ouest par les lots de terre Nos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.42, 43,44, 45, 46,47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.56, 57, 58, 59 et 60 de la subdivision officielle dudit lot No 899; et la partie du lot de terre No 125 de la subdivision officielle dudit lot No 899, mesurant 66 pieds de largeur par environ 1450.9 pieds de longueur, dans ses lignes est et ouest, contenant en sujœrficie environ quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent cinquante-neuf (lieds, mesure anglaise, et bornée au nord par le résidu du dit lot de terre No 125, appartenant à la Montreal Tramways Company ou représentants, à l'est par les lots de terre Nos 63.64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.79, 80.81, 82, 83, 84, 85, 86.87, 88.89 et 90 de la subdivision officielle dudit lot No 899, au sud par la rue Saint-Joseph, et à l'ouest par les lots de terre Nos 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104.105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118.119, 120.121.122^ et 123 de la subdivision officielle dudit lot No 899, sujettes, cesdites parties des lots Nos 62 et 125, aux servitudes de passage résultant de leur desti-tions comme rues par leur propriétaire et ses auteurs, et de leur indication comme telles au plan de surxlivision dudit lot No 899 et au livre de renvoi officiels déposés au bureau du Commissaire des terres de la Couronne et au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement des comtes d'Hochelaga et Jacques-Cartier, lors de la subdivision officielle d'une partie dudit lot No 899 en 1901.Tous ces lots et ces parties de lots de terre ci-dessus décrits sont maintenant compris dans la cité de Lachine.Pour être vendus a mon bureau, en la cité de Montréal, le QUATORZIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à DEUX heures de l'après-midi.lie shérif, L.-J.LEMIEUX.Montréal, 8 août 1917.3749\u201432-2 [Première publication, 11 août 1917.] FIERI FACIAS DE TERRIS.Cour supérieure.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir:! P\\ELLE LOUISE PA- No 5007.J U YETTE, fille majeure et usant de ses droite, demanderesse; vs EDOUARD LATREILLE, FILS, et EDMOND GRAVEL, commerçants, faisant affaires sous les nom et raison sociale de \"Montreal Wood & Coal Company\", défendeurs ; et L.-A.BEDARD, curateur au délaissement.898; and the lots Nos.96.97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 and 122, of the official subdivision of said lot No.899.All the above lots and parts of lots front on the western side of the lot No.125 of the official subdivision of said lot No.899, designated as and destined for a street and passage for the use of the subdivision lots of said lot No.899, fronting on such lot No.125 as aforesaid.That part of the lot of land No.62 of the official subdivision of said lot No.899, measuring 66 feet in width by about 1526.5 feet in length, it the eastern and western lines, containing al>out one hundred and three thousand and seventy three feet in superficial area, english measure ; hounded on the north by the residue of said lot No.62, belonging to the Montreal Tramways Company or representatives, on the east by the lots of land Nos.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.27, 28.29 and 30 of the official sulxlivision of said loi No.899, on the south by Saint Joseph street, on the west by the lots of land Nos.33, 34, 35, 36, 37, 38.39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.53, 54, 55, 56, 57,58, 59 and 60 of the official subdivision of the aforesaid lot No.899; and that part of said lot No.125 of the official subdivision of said lot No.899 measuring 66 feet in width by about 1450.9 feet in length, in its eastern and western lines, containing about ninety eight thousand four hundred and fifty nine feet in superficial area, english measure, bounded on the north by the residue of said lot of land Nc 125, belonging to the Montreal Tramways Company or representatives, on the east by the lots of land Nos.63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.72, 73, 74, 75, 76, 77.78, 79, SO.81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 and 90 of I he official subdivision of said lot No.899, on the south by Saint Joseph street, on the west bv the lots of land Nos.95,96,97,98,99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115.116, 117, 118, 119, 120, 121.122, and 123 of the official subdivision of said lot No.899, subject, said parts of lots Nos 62 and 125 to the servitudes of passages resulting from their destination as streets by their proprietors and authors, and of their designation as such on the subdivision plan of said lot No.899 and in the official hook of reference dejx>siled at the office of the Commissioner of Crown Lands and in the Registrar's office of the registration division of the counties of Hochelaga and Jacques Cartier at the time of the subdivision of part of said lot No.899, in 1901.All the lots and parts of lots above described are now included in the city of Laclùne.To be sold at mv office, in the city of Montreal, on the FOURTEENTH day of SEPTEMBER next, at TWO o'clock in the afternoon.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office.Montreal, 8th August, 1917.3750\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917J.FIERI FACIAS DE TERRIS.Superior court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit:\\ jV/IISS LOUISE PAYET-No.5007./ AVI TE, spinster in the full exercise of her rights, plaintiff; vs EDOUARD LATREILLE, JUNIOR, and EDMOND GRAVEL, traders, carrying on business under the name and style of \"Montreal Wood & Coal Company\", Defendants; and L.A.BEDARD, curator to the surrender of property made herein. 2066 Deux lots de terre ou emplacements ayant front sur ht rue Isabelle, (maintenant Chateaubriand), dans le quartier Saint-Denis, de la cité de Montréal, ci-devant connu sous le nom de village de Villeray, et coimus comme étant les numéros cent huit et cent neuf de la subdivision du lot numéro deux mille six cent trente (2t>30-108 et 109), des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Laurent\u2014avec les bâtisses y érigées et tous les droits et servitudes y attachés.ladites bâtisses jx>rtant les Nos civiques 2701 à 2705 rue Chateaubriand, et 935 à 949 Françoise Barry.I* tout pour être vendu en bloe comme formant un seul lot et une seule exploitation.Pour être vendu à mon bureau, en la cité de Montréal, le QUATORZIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à ONZE heures du matin.Le shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 8 août 1917.3751\u201432-2 (Première publication, 11 août 1917].FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Cour supérieure.\u2014District de Montréal.M&irréal, à savoir: \\ A LBERT HUDON.de-Nu.1030./ v\\ mandeur; vs DAME GEO R( il ANA ( '< )N NOLLY, veuve en premières noces de feu Joseph Godbout, fils, et maintenant épouse séparée de biens de Joseph-Antoine-I renée Amyot, et dûment autprisée par ce dernier et ALBINI RACINE, tous deux en Leur qualité d'exécuteurs testamentaires dudit feu Joseph Godbout, fils, défendeurs*.1.Un emplacement ayant front sur la rue Wurtele, en la cité de Montréal, et composé: a.du lot de terre connu et désigné sous le numéro deux de la résubdivision du lot numéro dix-neuf cent quarante et un de la subdivision officielle du lot numéro cent quarante-huit (148-1941-2), aux plan et livre de renvoi officiels du village incorporé d'Hochelaga; et 6.du lot de terre connu et désigné sous le numéro un de la résubdivision du lot numéro dix-neuf cent quarante-deux de la sulxlivision officielle-du lot numéro cent quarante-huit (148-1942-1), aux plan et livre de renvoi officiels susdits\u2014le tout avec bâtisses dessus érigées, ainsi que l'Usage en commun dans la ruelle sise en arrière desdits lots; 2.Un emplacement ayant front sur la rue Wurtele, en la cité de Montréal, et composé: a.du lot de terre coimu et désigné sous le numéro deux de la resubdivision du lot numéro dix-neuf cent quarante-deux de la subdivision officielle du lot numéro cent quarante-huit (148-1942-2),aux plan et livre de renvoi officiels du village incorporé d'Hochelaga; et 6.du lot de terre connu et désigné sous le numéro un de la resulxiivision du lot-numéro dix-neuf cent quarante-trois de la subdivision officielle du lot numéro cent quarante-huit (148-1943-1 ),aux plan et livre de renvoi officiels du village incorporé d'Hochelaga\u2014le tout avec bâtisses dessus érigées et le droit en commun dans la ruelle sise à l'arrière desdits lots.Pour être vendus à mon bureau, en la cité de Montréal, le CINQUIEME jour d'OCTOBRE prochain, à ONZE heures du matin.Le shérif.L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 29 août 1917.4023\u201435-2 .(Première publication, 1er septembre 1917].Those two lots of land fronting on Labelle street, (nowChateaubriand), in Saint Denis ward, of the city of Montreal, heretofore known under the name of village of Villeray.and known said lots as being the number! one hundred and eight and one hundred and nine of the subdivision of the lot numlx»r two thousand six hundred and tlurty (2680-108 and 109).of the official plan and book of reference of the parish of Saint Lament \u2014 with the buildings thereon erected and all the rights and servitudes attached thereto.The said buildings lxyiring civic Nos.2701 to 2705 in Chateaubriand street, and 935 to 94!» in Françoise Barry.The whole to Ixî sold in bloc as one single plot ot land.To lx» sold at my office, in the city of Mont n al, on the FOURTEENTH day of SEPTEMBER next, at ELEVEN o'clock in the forenoon.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office.Montreal.8th August, 1917.3752\u201432 2 [First publication, 11th August, 1917].FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TER I MS.Superior Court.- -District of Montrait.Montreal, to witïî ALBERT HUDON, No.1030./ r\\ plaintiff; vs DAME GEORGIAN A CONNOLLY, widow by marriage of the late Joseph Godbout, junior, and now wife separated as to property of Joseph-Antoine Irénée Amvot, and duly authorized by the latter and ALBINI RACINE, both in their quality of testamentary executors of said late Joseph Godbout, junior, defendants.1.That certain emplacement fronting on Wurtele street, in the city of Montreal, and composed : a.of the lot of land known and designated under the number two of the ré-subdivision of the lot number nineteen hundred and forty one of the official subdivision of the lot number one hundred and forty eight (148-1941-2), on the official plan and book of reference of the incorporated village of Hochelaga; and 6.of the lot of land known and designated under the number one of the resuhdi-vision of the lot number nineteen hundred and forty two of the official subdivision of the lot number one hundred and forty eight (148-1942-1).on the official plan and book of reference aforesaid \u2014the whole with the buildings thereon erected, together with the common use of the lane in real of said lots; 2.That certain emplacement fronting on Wurtele street, in the city of Montreal, and composed : a.of the lot of land known and designated under the number two ol the resubdivision of the lot number nineteen hundred and forty two of the official subdivision of the lot number one hundred and forty eight (148-1942-2), on the official plau and book of reference of the incorporated village of Hochelaga; and b.of the lot of land known and designated under the number one of the resubdivision of the lot number nineteen hundred and forty three of the official sulxlivision of the lot number one hundred and forty eight (148-1943-1), on the official plan and book of reference of the incorporated village of Hochelaga \u2014 the whole with the buildings thereon erected, together with the common use of the lane in rear of said lots.To be sold at my office, in the city of Montreal, on the FIFTH day of OCTOBER next, at ELEVEN o'clock in the forenoon.L.-J.LEMIEUX.Sheriff.Sheriff's office.Montreal, 29th August, 1917.4024\u201435-2 [First publication, 1st September, 19171. 2067 FIERI FACIAS DE TERRIS.Cour suj>érieure.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir: ^ À I,RIEN MESSIER No 1941./ t\\ r CHARLES-EDOUARD MESSIER, en leur qualité d'administrateurs et d'exécuteurs testamentaires de la succession de feAi Christophe Messier, demandeurs; vs 8YLVE8TRO D'AMBROSIO, défendeur et J.-O.LAROSE, curateur au délaissement.Deux lots de terre ayant front sur la rue Sherbrooke, en la cité de Montréal, connus et désignés sous les numéros cent et cent un de la subdivision officielle du lot No douze cent vingt-cinq (1225-100-101), aux plan et livre de renvoi officiels du quartier Sainte-Marie, en la cité de Montréal\u2014 avec servitudes actives et passives.Pour être vendus à mon bureau, en la cité de Montréal, le QUATRIEME jour d'OCTOBRE prochain, à ONZE heures du matin.Le shérif, L.-J.LEMIEUX.bureau du shérif.Montréal, 29 août 1917.4025\u201435-2 [Première publication, 1er septembre 1917).MANDAT DE CURATEUR.FIERI FACIAS DE TERRIS.Montreal, à sa voir:) CRNEST ST AMOUR, No 136./ *-* curateur aux biens de C.-KLIE DESCHENEAUX.failli.Deux emplacements ayant front sur la rue Ethel, au coin de la rue Régina.en la ville de Verdun, connus et désignés comme lots 131 et 132, aux plans de subdivision du lot No 3401 des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Montréal\u2014avec les bâtisses y érigées et les servitude^ y attachées, suivant titres, ainsi que le tout se tixruve présentement et avec droit dans la ruelle en arrière desdits emplacements.Un emplacement faisant front sur la rue Ethel, eu la ville de Verdun, connu et désigné comme étant la subdivision No 1 de la subdivision No 180 du lot No 3401, contenant 25 pieds de largeur par 75 pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins\u2014avec une maison y érigée et contenant trois flats.Pour être vendus à mon bureau, en la cité de Montréal, le QUATRIEME jour d'OCTOBRE prochain, à DEUX heures de l'après-midi.Le shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 29 août 1917.4027\u201435-2 [Première publication 1er septembre 1917].FIERI FACIAS DE TERRIS.Cour de circuit.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir :\\ ï ES COMMISSAIRES No 9010./ D'ECOLES DE LA MUNICIPALITE DU COTEAU SAINT-PIERRE, demandeurs; vs DELLE JULIA RAPP, fille majeure et usant de ses droits, anciennement de Montréal, maintenant de lieux inconnus, défenderesse.Un lot de terre situé dans la cité de Montréal, connu et désigné comme étant le lot de subdivision numéro 343 du lot officiel numéro 171, des plan et livre de renvoi officiels de la municipalité de la paroisse de Montréal; ledit lot borné en front par l'avenue Draper.Pour être vendu à mon bureau, en la cité de FIERI FACIAS DE TERRIS.Superior Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit:\\ ADRIEN MESSIER Xo.1941./ *\u2022 and CHARLES-EDOUARD MESSIER, both in their capacity of administrators and testamentary executors to the estate of the late Christophe Messier, plaintiff; vs SYLVESTRO D'AMBROSIO, defendant, and J.-O.LAROHE, curator to the surrender of property made herein.Two lots of land fronting on Sherbrooke street, in the city of Montreal, known and designated Under the numbers one hundred and one hundred and one of the official subdivision of the number twelve hundred and twenty five (1225-100 and 101), on the official plan and book of reference of Saint Mary's ward, in the city of Montreal\u2014 with the adtive and passive servitudes attached thereto.To be sold at my office, in the city of Montreal, on the FOURTH day of OCTOBER next, at ELEVEN o'clock in the forenoon.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office.Montreal, 29th August, 1917.4026\u201435-2 [First publication 1st September.1917].CURATOR'S WARRANT.FIERI FACIAS DE TERRIS.Superior Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit:\\ CRNEST ST.AMOUR.No.136./ *-* curator to the property of C.-ELIE DESCHENEAUX.insolvent.Two emplacements fronting on Ethel street, at the corner of Regina street, in the town of Verdun, known and designated as being the lots 131 and 132, on the subdivision plan of the lot No.3401 of the official plan and book of reference of the parish of Montreal\u2014with the buildings thereon erected and the servitudes attached, as per titles, as the whole now subsists and with the common use ot the lane in rear of said emplacements.Another emplacement fronting on Ethel street, in the town of Verdun, known and designated as being the sulxlivision No 1 of the sulxlivision No.180 of lot No.3401, containing 25 feet in width by 75 feet in depth, English measure and more or less \u2014with a house thereon erected containing three flats.To be sold at mv office, in the city of Montreal, on the FOURTH day of OCTOBER next, at TWO o'clock in the afternoon.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office.Montreal.29th August, 1917.4028\u201435-2 [First publication.1st September, 1917].FIERI FACIAS DE TERRIS.Circuit Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit :\\ rTHE SCHOOL COM-No.9610.j 1 MISSIONERS FOR THE MUNICIPALITY OF COTEAU SAINT PIERRE, plaintiffs ; vs DELLE JULIA RAPP, spinster in her legal capacity, formerly of Montreal, now of parts unknown, defendant.A lot of land situate in the city of Montreal, and known and distinguished as lot subdivision number 343 of lot official number 171, on the official plan and book of reference of the municipality of the parish of Montreal ; said lot bounded in front by Draper Avenue.To be sold at my office, in the city of Montreal, 2008 Montréal, le CINQUIEME jour d'OCTOBRE on the FIFTH day of OCTOBER next, at TEN prochain, à DIX heures de l'avant-midi.o'clock in the forenoon.Le shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 29 août 1917.4029\u201435-2 [Première publication, 1er septembre 1917.] L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office.Montreal, 29th AugUBt, 1917.4030\u201435-2 [First publication, 1st September, 1917.] FIERI FACIAS DE TERRIS.Cour de circuit.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir :\\ ï ES COMMISSAIRES No 9612./ L« D'ECOLES POUR LA MUNICIPALITE DU COTEAU SAINT-PIERRE, demandeurs ; vs EMILE ALEXANDER, défendeur.Un lot de terre connu et désigné comme étant le lot de subdivision No 295 du lot officiel No 162, des plan et livre de renvoi officiels de la municipalité de la paroisse de Montréal; ledit lot ayant front sur l'avenue Kensington, dans la cité de Montréal.Un lot de terre connu et désigné comme étant le lot de subdivision No 260 du lot officiel No 162, des plan et livre de renvoi officiels de la municipalité de la paroisse de Montréal; ledit lot ayant front sur l'avenue Madison, dans la cité de Montréal.Pour être vendus à mon bureau, en la cité de Montréal, le QUATRIEME jour d'OCTOBRE prochain, à MIDI.Le shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 29 août 1917.4031-35-2 [Première publication, 1er septembre 1917.] FIERI FACIAS DE TERRIS.Circuit Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit :\\ \"\"THE SCHOOL COM-No.9612.J 1 MISSIONERS FOR THE MUNICIPALITY OF COTEAU SAINT PIERRE, plaintiffs ; vs EMILE ALEXANDER, defendant.A lot of land known and designated as subdivision No.295 of lot official No.1(52, on the official plan and book of reference for the municipality of the parish of Montreal; said lot fronting ou Kensington Avenue, in the city of Montreal.A lot of land known and designated as subdivision lot No.260 of lot official No.162, on the official plan and book of reference for the municipality of the parish of Montreal; said lot fronting on Madison Avenue, in tne city of Montreal.To be sold at my office, in the city of Montreal, on the FOURTH dav of OCTOBER next, at NOON.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office.Montreal, 29th August, 1917.4032\u201435-2 [First publication, 1st September, 1917.] FIERI FACIAS DE TERRIS.Cour supérieure.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir: I DAUL-EMILE ROY, es.No 2799.J * qualité de curateur à Dame Marie-Louise St-Aubin, veuve de feu Calixte-M.Roy, demandeur; vs J.-B.TETRAULT, défendeur et TELESPHORE DE-PATIE, curateur au délaissement.1.Un lot de terre sis et situé en la cité de Maisonneuve, district de Montréal; borné en front par la rue Ontario, de la dite cité, connu et désigné sous le No 1313, de la resubdivision officielle de partie du lot primitif No 2 (p.2-1313), aux plan et livre de renvoi officiels du village incorporé d'Hochelaga, contenant vingt-neuf pieds de largeur par quatre-vingt dix-neuf pieds et dix pouces de profondeur dans une ligne, et cent pieds et un pouce dans rentre-ligne, mesure anglaise, et plus ou moins; borné en front par la rue Ontario, en arrière par une ruelle portant le No p.2-1316\u2014avec les bâtisses dessus construites et droit de passage dans la dite ruelle en commun; 2.Un lopin de terre situé en la dite cité de Maisonneuve, formant partie du lot No 1317, de la redivision officielle de partie du dit lot primitif No 2, sur les dits plan et livre de renvoi officiels du dit village incorporé d'Hochelaga (pt 2-1317), contenant treize pieds de largeur par vingt-sept pieds de profondeur; tenant devant au sud-est par une ruelle portant le No 2-1316, du côté sud-ouest par une autre ruelle portant le No 1334, de la dite redivision, en arrière par le No 2-1318, du côté nord-est par le reste du dit lot No 2-1317\u2014avec une écurie dessus construite.Pour être vendus à mon bureau, en la cité de FIERI FACIAS DE TERRIS.Superior Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit:\\ DAUL-EMILE ROY, es.No.2799.I » qualité, curator to Dame Marie-Ix>uise St-Aubin, widow of the late Calixte-M.Roy, plaintiff; vs J.-B.TETRAULT, defendant, and TELESPHORE DEPATIE, curator to the surrender.1.A lot of land being and situate in the city of Maisonneuve, district of Montreal; bounded in front by Ontario street, of the said city, known and designated under the No.1313, of the official resubdivision of part of the primitive lot No.2 (pt.2-1313), on the official plan and book of reference of the incorporated village of Hochelaga, containing twenty nine feet in width by ninety nine feet and ten inches in depth on one line, and one hundred feet and one inch on the between line, English measurement, and more or less; bounded in front by Ontario street, in the rear by a lane bearing the No.p.2-1316\u2014with the buildings thereon erected and right of way in the said lane in common; 2.A parcel of land situate in the said city of Maisonneuve, forming part of the lot No.1317, of the official redivision of part of the said primitive lot No.2, on the said official plan and book of reference of the said incorporated village of Hochelaga (pt 2-1317), containing thirteen feet in width by twenty seven feet in depth; bounded in front to the southeast by a lane bearing the No.2-1316, on the southwest side by another lane bearing the No.1334, of the said redivision, in the rear by the No.2-1318, on the northeast side by the remainder of the said lot No.2-1317-with a stable thereon erected.To be sold at my office, in the city of 2060 Montréal, le CINQUIEME jour d'OCTOBRE prochain à MIDI.I>e shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif, Montréal, 29 août 1917.4033-35-2 [Première publication, 1er septembre 1917.1 FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Cour supérieure.\u2014District de Montréal.Montréal.à savoir:! A LBERT HUDON, de-No 999./ r\\ MANDEUR;vs DAME CJEORGIANA CONNOLLY, veuve de Joseph Godbout.fils, et maintenant éj)ouse séparée de biens de Joseph-Antoine-Irénée Amyot, otet duement autorisée par ce dernier,et ALBINI RACINE es qualité, défendeurs.1.Un emplacement ayant front sur la rue Wurtele, dans la cité de Montréal, connu et désigné sous le numéro deux de la re-subdivi-sion du lot numéro dix-neuf cent quarante-trois de la subdivision officielle du lot numéro cent quarante-huit (148-1943-2), aux plan et livre de renvoi officiels du village d'Hochelaga\u2014avec bâtisses dessus érigées et le droit en commun, dans la ruelle sise à l'arrière du dit lot; 2.Un emplacement ayant front sur la rue Wurtele; dans le quartier Hochelaga, en la cité de Montréal, et composé de la partie nord-ouest d'un lot de terre connu et désigné sous le numéro dix neuf cent quarante-neuf de la subdivision officielle du lot numéro cent quarante-huit (148-1949), aux plan et livre de renvoi officiels du village d'Hochelaga, mesurant dix-sept pieds et six pouces de largeur par quatre-vingts pieds de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins, sans garantie de mesure précise, borné en front, la dite partie par la rue Wurtele, en arrière par une ruelle, d'un côté, au nord-ouest par le lot numéro cent quarante-huit-dix-neuf cent cinquante (148-1950), et de l'autre côté, au sud-est par le surplus du même lot 14S-1929\u2014avec une maison portant les numéros civiques 109, 111 et 113 de la dite rue Wurtele, et autres bâtisses et dépendances dessus construites.Pour être vendus à mon bureau, en la cité de Montréal, le CINQUIEME jour d'OCTOBRE prochain, à DEUX heures de l'après-midi.Le shérif, L.-J.LEMIEUX, Bureau du shérif, Montréal, 29 août 1917.4035\u201435-2 [Première publication, 1er septembre 1917.] FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Cour supérieure.\u2014District de Montreal.Montréal, à savoir :\\ ALBERT HUDON, No 4251.i marchand, deV cité et district de Montréal, demandeur; vs DAME GEORGIANA CONNOLLY, de la ville de Westmount,district de Montréal, épouse séparée de biens de Joseph-Antoine-Irénée Amyot, marchand, du même lieu, en sa qualité d'exécutrice testamentaire de feu Joseph Godbout, fils, en son vivant du même lieu.et ALBINI RACINE,comp-table, des cité ot district de Montréal, en leur qualité d'exécuteurs testamentaires de feu Joseph Godbout, fils, et ledit Joseph-Antoine-Irénée Amyot, pour autoriser soil épouse aux fins des présentas, défendeurs es-qualité.Montreal, on the FIFTH day of OCTOBER next, at NOON.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office, Montreal, 29th August, 1917.4034\u201435-2 [First publication, 1st September, 1917.] FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Superior Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit:\\ A LBERT I IE DON.plain-No.999.f O tiff; vs DAME GEORGIANA CONNOLLY, widow of Joseph Godbout, junior, and now wife separated as to property of Joseph-Antoine-Irénée Amyot, and duly authorized by the latter, and ALBINI RACINE, es qualité, defendants.1.An emplacement fronting on Wurtele street, in the city of Montreal, known and designated under the number two of the re subdivision of the lot number nineteen hundred and forty tliree of the official subdivision of the lot number one hundred and forty eight (148-1943-2), on the official plan and book of reference of the village of Hochelaga\u2014with buildings thereon erected and the right in common in the lane situate at the rear of the said lot; 2.An emplacement fronting on Wurtele street, in Hochelaga ward, of the city of Montreal, and composed of the northwest part of a lot of land known and designated under the number nineteen hundred and forty nine of the official subdivision of the lot number one hundred and forty eight (148-1949), on the official plan and book of reference of the village of Hochelaga, measuring seventeen feet and six inches in width by eighty feet in depth, English messurement, more or less, without warranty of exact measurement, bounded in front the said part by Wurtele street, in the rear by a lane, on one side to the north west by the lot number one hundred and forty eight -nineteen hundred and fifty (148-1950).and on the south east by the surplus of the same lot 148-1929\u2014with a house bearing the civic numbers 109, 111 and 113, of the said Wurtele street, and other buildings and dependencies thereon erected.To be sold at mv office, in the citv of Montreal, on the FIFTH day of OCTOBER next, at TWO o'clock, in the afternoon.L.-J.LEMIEUX.Sheriff.Sheriff's office.Montreal.29th August.1917.4036\u201435-2 [First publication, 1st September, 1917].FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Superior Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit:\\ ALBERT HUDON, No.4251./ merchant, of the city and district of Montreal, plaintiff; vs DAME GEORGIANA CONNOLLY, of the town of Westmount, district of Montreal, wife separated as to property of Joseph-Antoine-Irénée Amyot, merchant, of the same place, in her quality of testamentary executrix of the late Joseph Godbout, junior, in his lifetime of the same place, and ALBINI RACINE, accountant, of the city and district of Montreal, in their quality of testamentary executors of the late Joseph Godbout, junior, and the said Joseph-Antoine-Irénée Amyot, to authorize his wife for the purposes hereof, Defendants es-qualité.i 2070 1.Un emplacemttit ayant front sur la rue Wurtele, en la cité de Montréal, connu et désigné sous le numéro deux de la ré-subdivision du lot numéro dix-neuf cent quarante de la subdivision officielle du lot numéro ceSit quarante-huit (148-1940-2), aux plan et livre de renvoi officiels du village d'Hochelaga\u2014avec bâtisses dessus érigées, ainsi que l'usage en commun dans la ruelle sise a l'arriére dudit lot; 2.Un emplacement ayant front sur la me Wurtele, en la cité de Montréal, et composé: a.du lot de terre connu et désigné sous le numéro un de la ré-subdivision du lot numéro dix-neuf cent quarante et un de la subdivision officielle du lot cent quarante-huit (148-1941-1), aux plan et livre de renvoi officiels du village d'Hochelaga; et b.du lot de terre connu et désigné sous le numéro trois de la ré-subdivision du lot numéro dix-neuf cent quarante de la subdivision officielle du lot numéro cent quarante-huit (148-1940-3), aux plan et livre de renvoi officiels susdit\u2014le tout avec bâtisses dessus érigées et avec droit en commun dans la ruelle sise à l'arrière desdits lots.Pour être vendu à mon bureau, en la cité de Montréal, le CINQUIÈME jour d'OCTOBRE prochain, à TROIS heures de l'après-midi.Le shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 29 août 1917.4037\u201435-2 [Première publication.1er septembre 1917J.FIERI FACIAS DE TERRIS Cour supérieure.\u2014District de Montréal.Montréal, à savoir: \\ ISAIE DUGAS, deman-No 1232./ 1 deur ; vs DAMASE LAPOINTE, défendeur.Un lot de terre vacant, ayant front sur la rue Saint-Hubert, en la cité de Montréal, connu et désigné comme étant le lot No deux cent cinquante-six.subdivision officielle du lot originaire No quatre cent quatre-vingt-neuf (489-256), des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse du Sault-au-Récollet, contenant vingt-cinq pieds de largeur par quatre-vingt-sept pieds de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins\u2014avec tous droits inhérents au susdit lot de terre.Pour être vendu à mon bureau, en la cité de Montréal, le QUATRIEME jour d'OCTOBRE prochain, a DLX heures du matin.Le shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 29 août 1917.4030\u201435-2 [Première publication, 1er septembre 1917.] 1.An emplacement fronting on Wurtele street, in the city of Montreal, known and designated under the number two of the resubdivision of the lot number nineteen hundred and forty of the official subdivision of the lot number one hundred and forty eight (148-1940-2), on the official plan and book of reference of the village of Hochelaga \u2014with buildings thereon erected, and also the use; in common in the lane situate at the rear of the said lot; 2.An emplacement fronting on Wurtele street, in the city of Montreal, and composed: a.of the lot of land known and designated under the number one of the resubdivision of the lot number nineteen hundred and forty one of the official subdivision of the lot one hundred and forty eight (148-1941-1), on the official plan and book of reference of the village of Hochelaga; and b.of the lot of land known and designated under the number three of the rosubdivision of the lot number nineteen hundred and forty of the official subdivision of the lot number one hundred and forty eight (148-1940-3), on the aforesaid official plan and book of reference\u2014the whole with buildings thereon erected and with right in common in the lane situate at the rear of the said lots.To be sold at my office, in the citv of Montreal, on the FIFTH day of OCTOBER next, at THREE o'clock in the afternoon.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office.Montreal.29th August.1917.4038\u201435-2 [First publication.1st September, 1917].FIERI FACIAS DE TERRIS Superior Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit: \\ ISAIE DUGAS, plaintiff: No.1232./ 1 vs DAMASE LAPOINTE, defendant.A lot of vacant land fronting on Saint Hubert street in the city of Montreal, known and designated as being the lot number two hundred and fifty six, official sulxlivision of the primitive lot number four hundred and eighty nine (489-256), on the official plan and book of reference of the parish of Sault-au-Récollet, containing twenty five feet in width by eighty seven feet in depth, English measurement, more or less\u2014with all inherent rights in the aforesaid lot of land.To be sold at mv office, in the citv of Montreal, on the FOURTH day of OCTOBER next, at TEN o'clock in the forenoon.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office.Montreal, 29th August, 1917.4040\u201435-2 [First publication, 1st September, 1917.] FIERI FACIAS DE TERRIS.Montréal, â savoir :) T OSWALD HAND-No 2937.I J \u2022 FIELD, demandeur; vs HENRI PELADEAU et al, défendeurs.Comme appartenant a Hector Péladeau, l'un desdits défendeurs.I-.es lots de terre situés en la cité de Montréal, bornés en front par mie rue projetée et étant le No 31 de la sulxlivision du lot No 22, des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse du Sault-au-Récollet, connus et désignés comme étant les numéros 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 de la subdivision du lot No 22, des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse du Sault-au-Récollet.FIERI FACIAS DE TERRIS.Superior Court.\u2014District of Montreal.Montreal, to wit :\\ I OSWALD HAND-No.2937.J J \u2022 FIELD, plaintiff ; vs HENRI PELADEAU et ai., defendants.As belonging to Hector Peladeau, one of the aforesaid defendants.Those certain lots of land situated in the city of Montreal, fronting on a projected street anil being the No.31 of the subdivision of the lot No.22, of the official plan and lxx>k of reference of the parish of Sault-au-Récollet, known and designated as being the numbers 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 of the subdivision of the lot No.22, of the official plan and book of reference of the parish of Sault-au-Récollet. 2071 Pour être vendus à mon bureau, en la cité de Montréal, le QUATRIEME jour d'OCTOBRE prochain, à TROIS heures de l'après-midi.I^e shérif, L.-J.LEMIEUX.Bureau du shérif.Montréal, 29 août 1917.4041\u201435-2 [Première publication, 1er septembre 1917.] OTTAWA FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS Cour supérieure.\u2014District de Terrebonne.Ottawa, à savoir:! I A BANQUE PROVIN-No581.J L.CIALE DU CANADA, demanderesse ; contre FRED.-G.SIMS et al, défenaeurs, *\\ savoir : Toute la maison et les autres bâtisses construites sur partie du lot No 1 du quartier No 5 de la cité de Hull, dans le district d'Ottawa, ainsi que les droit, titre, intérêt, prétention et réclamation du défendeur, Henry-J.Sims sur ledit terrain mesurant un acre de superficie; borné au nord par la rivière Gatineau, à l'est par la partie dudit lot occupée par un club, à l'ouest par le résidu dudit lot, et au sud par une autre portion du même lot, propriété de la succession de feu Dame Hannah Wright, aussi les droit, titre, intérêt et.prétention sur ladite maison et la propriété appartenant et dévolus au défendeur, Henry-.!.Sims.Pour être vendus à mon bureau, en la cité de Hull, le DEUXIEME jour d'OCTOBRE prochain, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif, C.-M.WRIGHT.Bureau du shérif.Hull, 16 août 1917.4017\u201435-2 [Première publication, 1er septembre 1917.] MANDAT DE CURATEUR.FIERI FACIAS DE TERRIS Cour supérieure.\u2014District d'Ottawa.Ottawa, à savoir:! TEREMIE DUFRESNE, No 4570./ J failli, et JOSEPH-EUGENE COLTTURE, curateur et requérant, à savoir: 1.Un lopin de terre situé dans la cité de Hull, dans les comté et district d'Ottawa, étant le lot numéro 388 et la partie sud du lot numéro 389 du quartier numéro quatre, de ladite cité de Hull, mesurant ensemble 98 pieds de largeur par 99 de profondeur, plus ou moins\u2014avec les bâtisses dessus construites, située sur l'avenue Champlain.2.Un lopin de terre situé dans ladite cité de Hull, dits comté et district, étant la partie nord du lot numéro 389, et la partie sud du lot numéro 384 du quartier numéro quatre, de ladite cité de Hull, mesurant 46 pieds de largeur par 99 pieds de profondeur, plus ou moins\u2014avec les bâtisses dessus construites, situé sur l'avenue Champlain.Pour être vendus à mon bureau, en la cité de Hull, le DEUXIEME jour d'OCTOBRE prochain, à DIX heures et DEMIE de l'avant-midi.Le shérif, C.-M.WRIGHT.Bureau du shérif.Hull, 27 août 1917.4019\u201435-2 [Première publication, 1er septembre 1917.] To be sold at my office, in the city of Montreal, on the FOURTH day of OCTOBER next, at THREE o'clock in the afternoon.L.-J.LEMIEUX, Sheriff.Sheriff's office.Montreal, 29th August, 1917.4042\u201435-2 [First publication, 1st September, 1917.] OTTAWA FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS Superior Court.\u2014District of Terrebonne.Ottawa, to wit: 1 ï A BANQUE PROVIN-No.581./ L* CIALE DU CANADA, plaintiff; against FRED.-G.SIMS et al, defendants, to wit: All that house and other buildings erected on part of lot No.1 of ward No.5 of the city of Hull, in the district of Ottawa, and all the right, title interest, claim and demands of the defendant, Henry-J.Sims on said land containing one acre in superficies; bounded to the north by the Gatineau River, east by that portion of said lot occupied by a club, west by the residue of said lot, and south by another portion of the same lot the property of the estate of the late Dame Hannah Wright, and all the right, title, interest and claim upon the said house and property belonging to and vested in the defendant, Henry-J.Sims.To lie sold at my office, in the city of Hull, on the second oay of OCTOBER next, at TEN o'clock in the forenoon.C.-M.WRIGHT, Sheriff.Sheriff's office.Hull, 16th August, 1917.4018\u201435-2 [First publication, 1st September, 1917.] CURATORS WARRANT FIERI FACIAS DE TERRIS Superior Court.\u2014District of Ottawa.Ottawa, to wit: ) TEREMIE DUFRESNE, No.4570./ J insolvent, and JOSEPH-EUGENE COUTURE, curator and petitioner, to wit : 1.A piece of land situate in the city of Hull, in the county and district of Ottawa, being the lot number 388 and the south part of the lot number 389 of ward numljer four, of the said city of Hull, measuring together 98 feet in width by 99.feet in depth, more Or less,\u2014with the buildings thereon erected, situate on Champlain Avenue.' 2.A piece of land situate in the said city of Hull, said comity and district, being the north part of the lot number 389, and the south part of the lot number 384 of ward number four.of the said city of Hull, measuring 4(5 feet, in width by 99 feet in'depth, more or less\u2014with the buildings thereon situate on Champlain Avenue.To be sold at my office, in the city of Hull, on the SECOND day of OCTOBER next, at HALF PAST TEN o'clock in the forenoon.C.-M.WRIGHT, Sheriff.Sheriff's office.HuU, 27th August, 1917.4020\u201435-2 [First publication, 1st September, 1917.] 2072 FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS Cour supérieure.\u2014District d'Ottawa.Ottawa, a savoir: I JEAN - PIERRE ROUX No 3844./ J et al, demandeurs ; contre ALFRED RELANGER et al, défendeurs.Saisis comme appurtenant au défendeur, Antoi-ne-O.Bélanger, â savoir: _ 1.Deux lots situés au village de Papineauville, district d'Ottawa; bornés en front par la rue Viger, connus et désignés sous les numéros deux cent soixante-quinze et deux cent soixante-seize (275-270), des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Angélique, dans ledit district d'Ottawa \u2014 avec la maison et les déjxm-dances s'y rattachant construites sur lesdits lots, le8elonging to the defendant, Antoine-O.Bélanger, to wit: 1.Two certain lots situated in the village of Papineauville, district of Ottawa; bounded in front by Viger street, and known and designated as numbers two hundred seventy five and two hundred seventy six (275 and 276), on the official plan and book of reference for the parish of Saint Angélique, in said district of Ottawa\u2014with, the house and appurtenances belonging and erected on said lots, said lots making one exploitation only, and to be sold together (en bloc) as a whole.2.Another certain lot of land situated in the said village of Papineauville; bounded in front by Metcalfe street, and known and designated as number one hundred and ninety two (192), on the official plan and book of reference for the said pariah of Saint Angélique\u2014.with a house thereon erected, said house facing the public square.To l>e sold at the parochial church door of the parish of Saint-Angelique-de-Papineauville, on the THIRD day of OCTOBER next.ata QUARTER PAST TEN oi the clock in the forenoon.C.-M .WRIGHT.Sheriff.Sheriff's office.Hull, 28th August, 1917.4022\u201435-2 [First publication, 1st September, 1917].FIERI FACIAS DE TERRIS.Magistrate's Court.\u2014District of (Mama, Ottawa, to wit : \\  NTOINE SANSCAR-No.2032.) r\\ TIER, plaintiff; against EVANGELISTE alias ALEXANDRE KINGSBURY, defendant, to wit : The dwelling being No.68 Carillon street, and other buildings erected on one third of cadastral lot number one hundred and twenty (120), of ward No.two, of the city of Hull, in said district of Ottawa.To be sold at my office, in the city of Hull, on the ELEVENTH day of SEPTEMBER next, at TEN o'clock in t he forenoon.C.-M.WRIGHT.Sheriff.Sheriff's office.Hull, 7th August, 1917.3784\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917] QUEBEC FIERI FACIAS.Quebec, to wit :\\ y*VES MONTREUIL.of No.344.J * the city of Quebec, notary public ; against J.-ALPHONSE LEFEBVRE, agent, of the city and district of Montreal, to wit : All the rights and interests of the defendant, J.-Alphonse Lefebvre, in and upon the subdivisions Nos.1 (one), 2 (two), 3 (three), 4 (four), 5 (five), 6 (six), 7 (seven), 8 (eight), 9 (nine), 10 (ten), 11 (eleven), 12 (twelve), 13 (thirteen), 14 (fourteen), 15 (fifteen) and 10 (sixteen), of lot No.514 (five hundred and fourteen), of the official cadastre for Saint-Roch-North, now Limoilou ward, of the city of Quebec, and on the north part of the single division No.27 (twenty seven), of said lot No.514 (five hundred and fourteen), of same cadastre ; bound- 2073 numéros, au nord par le chemin public et au sud à l'autre partie du No 27, tel que le tout eBt actuellement, sans exception ni réserve, mais sans aucune garantie\u2014circonstantes et dé|xmdances.Pour être vendus à mon bureau, en la cité de Québec, le CINQUIEME jour d'OCTOBRE prochain, à DIX heures du matin.\\jc shérif, CLEOPHAS BLOUIN.Bureau du shérif.Québec, 30 août 1917.4043\u201435-2 [Première publication.1er septembre 1917.] [Deuxième publication, 15 septembre 1917.] ALIAS FIERI FACIAS.Québec, à savoir:) THEOPHILE VER-No 2189./ A METTE, de la cité de Québec, employé civil; contre JOACHIM FORTIN, ingénieur civil, de l'endroit appelé Bagot-ville, P.-V.FORTIN et ALFRED-J.FORTIN, tous deux de la paroisse de Saint-Henri, dans le comté de Lévis, à savoir: 1.Partie du lot No 113-B (cent treize-B),du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Henri, comté de Lévis, étant un lopin de terre situé sur le côté ouest du chemin public mesurant 04 pieds anglais de largeur à partir de la ligne de Ferdinand Turgeon, ou ayants cause, à aller aux poteaux sud de la barrière, sur une profondeur qu'il jxmt y avoir à partir du chemin public, du côté est, à aller à la rivière Etchemin; borné à l'est par le chemin public, au sud par Ferdinand Turgeon, ou ayants cause, à l'ouest par la rivière Etchemin, et au nord par le reste dudit lot No 113-B\u2014avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.2.Le lot No 131 (cent trente et un),du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Henri, comté de Lévis, étant un terrain situé sur le chemin Bois Clair, contenant environ 0 arpents et 34 perches en superficie ; borné au nord à Théodule Beaudoin ou ses ayants cause, à l'est partie à Théodule Beaudoin ou ses ayants cause, et partie au terrain de Joseph Duquet, Damas Blouin.Edmond et Adolphe Fortin, Léon Duquet et Philias Boivin, ou leurs ayants cause, au sud au chemin Bois Clair, partie au terrain de Benjamin Boutin et ses ayants cause, et un cours d'eau qui sépare ledit terrain d'Adelina Beaulé, et ses ayants cause, à l'ouest â la rivière Etchemin, avec un droit de passage sur l'emplacement de Joseph Duquet, ou ses ayants cause, et tous droits, réserves ou servitudes sur le lot No 124 dudit cadastre de Saint-Henri\u2014avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.A distraire dudit lot No 131 la partie vendue par Adélina Beaulé à Théodule Beaudoin.Pour être vendus à la porte de l'église paroissiale de Saint-Henri, comté de Lévis, le VINGTIEME jour de SEPTEMBRE prochain, â DIX heures du matin.Le shérif, CLEOPHAS BLOUIN.Bureau du shérif.Québec, 16 août 1917.3843\u201433-2 [Première publication, 18 août 1917].[Deuxième publication, 1er septembre 1917].ed on the west; by the lands of the Hôtel-Dieu, on the east by the aforesaid numbers, on the north by the public road and on the south by the other part of No.27, as the whole now subsists, without any exception or reserve, but without any warranty\u2014circumstances and dependencies.To be sold at my office, in the city of Quebec, on the FIFTH day of OCTOBER next, at TEN o'clock in the forenoon.CLEOPHAS BLOUIN, Sheriff.Sheriff's office.Quelxjc, 30th August, 1917.4044\u201435-2 [First publication, 1st September, 1917.] [Second publication, 15th September, 1917.] ALIAS FIERI FACIAS.Quebec, towit:\\ \"\"THEOPHILE VERMETTE, No.2189.I *¦ civil employee, of the city of Quebec; against JOACHIM FORTIN, civil engineer, of the place called Bagotville, P.-V.FORTIN and ALFRED-J.FORTIN, both of the parish of Saint Henri, in the county of Levis, to wit: 1.That certain part of lot No.113-B (one hundred and thirteen-B), of the official cadastre for the parish of Saint Henri, county ot Levis, being a parcel of land situate on the western side of the public road and measuring 64 feet, english measure in width from the line of Ferdinand Turgeon or assigns to the south post of the gate, by whatever depth there may be from the public road, on the eastern side, to the Etchemin river; bounded on the east by the public road, on the south by Ferdinand Turgeon or assigns, on the west by the Etchemin river, and on the north by the residue of said lot No.113-B\u2014with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.2.That certain lot No.131 (one hundred and thirty one),of the official cadastre for the parish ot Saint Henri, county of Levis, being a lot of land situate on Bois Clair road, containing about 6 arpents and 34 perches in superficies; bounded on the north by Theodule Beaudoin or assigns, on the east partly by Theodule Beaudoin or assigns and partly by the land of Joseph Duquet.Damas Blouin, Edmond and Adolphe Fortin, Leon Duquet and Philias Boivin or assigns, on th esouth by the Bois Clair road, partly by the land of Benjamin Boutin or assigns and by the stream separating the said lot from that of Adelina Beaule or assigns, on the west by the Etchemin river, with a right of way on the emplacement of Joseph Duquet or assigns, and all other rights, reserves or servitudes on lot No.124 of said cadastre of Saint Henri\u2014with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be deducted from said lot No.131, the part thereof sold by Adelina Beaule to Théodule Beaudoin.To be sold at the parochial church door of Saint Henri, county of Levis, on the TWENTIETH day of SEPTEMBER next, at TEN o'clock in the forenoon.CLEOPHAS BLOUIN, Sheriff.Sheriff's office.Quebec, 16th August.1917.3844\u201433-2 [First publication, 18th August, 1917].[Second publication, 1st September, 1917]. 2074 RIMOUSKI FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Cour supérieure.District de Rimouski, I DELLA VANCE & No 5556./ D CIE ; vs JULES BRISSON, Sainte-Blandiiie, savoir: Tous droits d'occupation, de défrichement, de préemption, améliorations et autres du défendeur sur la moitié est du lot numéro quarante-et-un au cadastre officiel de partie du canton Neigette, rang trois, paroisse de Sainte-Blandine\u2014avec bâtisses.Pour être vendus â la porte de l'église de Sainte-Blandine, le DOUZE SEPTEMBRE prochain 1917, à ONZE heures de l'avant-midi.I,e shérif, CHS D'ANJOU.Bureau du shérif.Rimouski.8 août 1917.3765\u201432-2 [Première publication, 11 août 1917].FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Cour de circuit.District de Rimouski,! I A COMPAGNIE No 2718./ L« DESJARDINS; vs HERMENEGILDE GAGNE, CAPUCINS, savoir: Les lots numéros quarante-deux A et B, au cadastre officiel du premier rang du canton Romieu\u2014avec bâtisses; â distraire le terrain de Jos.Ianglois.Pour être vendus au bureau d'enregistrement, à Matane, le QUATORZE SEPTEMBRE prochain 1917, à MIDI.Le shérif, CHS D'ANJOU.Rimouski, 8 août 1917.3769\u201432-2 [Première publication, 11 août 1917].ROBERVAL FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Superior court.District of Rimouski, \\ DELLA VANCE k No.5556./O CIE; «g JULES BRISSON, Sainte Blandine.to wit- All rights of occupation, clearing, preemption, improvement and other of the defendant on the east half of lot number forty one on the official cadastre ol part of the township Neigette, range three, parish of Sainte Blandine\u2014with buildings.To be sold at the church door of Sainte Blandine, on the TWELFTH of SEPTEMBER next, 1917, at ELEVEN o'clock in the forenoon.CHS D'ANJOU, Sheriff Sheriff's office.Rimouski.8th August, 1917.3766\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917].FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Circuit court.District of Rimouski, \\ I A COMPAGNIE No.2718.) L« DESJARDINS; vs HERMENEGILDE GAGNE, CAPUCINS, to wit: Lots numbers forty two A and B, on 'he official cadastre of the first range of the township Romieu\u2014with buildings; to be withdrawn the lot of land of Jos.Langlois.To be sold at the registry office, at Matane, on the FOURTEENTH of SEPTEMBER next, 1917, at NOON.CHS D'ANJOU, Sheriff.Rimouski, 8th August, 1917.3770\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917].ROBERVAL MANDAT Cour supérieure.\u2014District de Montréal.Province de Québec, \\ P\\E LAVAL DAIRY No 2653, à savoir: ) SUPPLY Co.LTD, corps politique et incorporé ayant son bureau principal et sa place d'affaires principale pour la province de Québec, dans les cité et district de Montréal; vs DIDIER CASTONGUAY, de Saint-Félicien, Lac Saint-Jean, cultivateur.a.Une terre située en la paroisse de Saint-Félicien, et une petite partie en la paroi&se de Saint-Prime, comté du lac Saint-Jean, contenant en superficie trois cents acres, plus ou moins, comme et désignée comme étant les lots numéros trente-sept, trente-huil et trente-neuf (37, 38 et 39), des plan et livre de renvoi officiels du -adastre pour le deuxième rang du canton Ashuapmouchouan\u2014 avec ensemble les bâtisses dessus construites, appartenances et dépendances, sauf à distraire le terrain du James Bay & Eastern Railway, et sauf à distraire dudit lot numéro trente-huit un emplacement de trois arpents en superficie, plus ou moins, ou se trouvent les bâtisses qui appartenaient ci-devant â John-H.Cummings; b.Aussi un morceau de terrain contenant environ deux arpents en superficie e1 faisant partie du lot rie terre maintenant connu et désigné sous le numéro trente-neuf-A (ptie 39-a), des plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour le premier rang du susdit canton Ashuapmouchouan, appar- WARRANT Superior Court.\u2014District of Montreal.Province of Quebec.) T\\E LAVAL DAIRY No.2653, to wit: / U SUPPLY CO.LTD, body politic and corporate having its principal office and its principal place of business in the province of Quebec, in the city and district of Montreal; vs DIDIER CASTONGUAY, of Saint Félicien, Lake Saint Jolin, farmer.a.That certain land situated in the parish of Saint Félicien, and a small part thereof in the parish of, Saint Prime, comity of Lake Saint Jolui, containing in area three hundred acres, more or less, known and designated as being the lots numbers thirty seven, tliirty eight and thirty nine (37, 38 and 39), of the official cadastral plan and book of reference for the second range of Ashuapmouchouan townsliij)\u2014together with the buildings thereon erected, appurtenances and dependencies, to be deducted therefrom the land of the James Bay & Eastern Railway, and to be deducted also from lot number thirty eight an emplacement of three arpents in superficies, more or less, where are erected the buildings formerly owned by John-H.Cummings: b.Also a parcel of land of about two arpents in superficies and forming part of the lot of land now known and designated under the number thirty nine A (Pt.39a), of the official cadastral plan and book of reference of the firsc range of the aforesaid Ashuapmouchouan township, appurte- 2075 finances et défiendances ; borné vers le sud au deuxième rang dudit canton, vers le nord au chemin public, vers l'est au lot numéro trente-huhVB (38-6), et vers l'ouest a la rivière à l'Ours.Pour être vendu à la porto de l'église de la paroisse de Saint-Félicien, comté du Lac Saint-.lean, MARDI, le ONZIEME jour de SEPTEMBRE 1917, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.GEO.LEVESQUE.Bureau du shérif.Roberval, 7 août 1917.3753\u201432-2 [Première publication, 11 août 1917.] MANDAT DU CURATEUR.Cour mtpéritwe.Province de Quelle, | iSANS l'affaire de J.-District de Roberval, ARTHUR GUE- Xo 1122.' RIN, marchand, «le Saint-Jérôme, failli ; et CHS-A.SYLVESTRE, ourateur, â savoir : 1.Un magasin à meubles a deux étages mesurant environ trente pieds de largeur sur quatre-vingts pieds de longueur, construit sur la demi sud du lot de terre connu et désigné sous ie numéro quarante-six-B-trente-trois (l/-> sud 4(i6-33), du cadastre officiel pour le premier rang du canton Caron, mesurant environ quarante pieds de front sur environ quatre-vingt-six pieds de profondeur ; borné en front vers l'ouest au chemin public, en arrière vers l'est au lot numéro quarante-six-B-trente-sept, joignant au nord le terrain de Frédéric Thibault, et au sud l'emplacement de Honoré Bilodeau ; 2.La demi sud du lot de terre connu et désigné sous le numéro quarante-s'ix-B-trente-quatre {x/i sud 466-31), du cadastre officiel pour ledit premier rang du canton Caron\u2014avec les bâtisses dessus construites; ledit terrain mesurant environ quarante pieds de front sur quatre-vingt-sept pieds de profondeur ; borné en front, vers l'ouest au chemin public, en arrière vers l'est au lot numéro quarante six-B trente-sept, joignant au nord à l'emplacement de Honoré Bilodeau, et au sud à l'emplacement de Stanislas Fortin ; 3.Un terrain mesurant environ cent soixante pieds de front sur quatre-vingt-quinze pieds de profondeur, faisant partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro'quarantc-six-B trente-sept (Ptie 466-37), du cadastre officiel pour ledit premier rang du canton Caron, dans le comté du Lac Saint-Jean\u2014avec un garage dessus construit, de vingt pieds par vingt-cinq pieds ; borné vers l'est au terrain de André Néron, vers l'ouest partie au terrain de Frédéric Thibault, partie aux deux terrains ci-dessus décrits, et partie au terrain de Honoré Bilodeau, joignant au nord le terrain de Joseph lefebvre ou représentants, et au sud au terrain de Stanislas Fortin.Pour être vendus à la porte de l'église de la paroisse de Saint-Jérôme (Métabetchouan), Lac Saint-Jean, MERCREDI, le DOUZIEME jour de SEPTEMBRE 1917, à ONZE heures de l'avant-midi.Le shérif, GEO.LEVESQUE.Bureau du shérif.Roberval, 7 août 1917.3771\u201432-2 [Première publication, 11 août 1917.] nances and dependencies ; bounded on the south by the second range of said townsliip, on the north by the public road, on the east by the lot number thirty eight B (386), and on the west by the river à l'Ours.To be sold at the church door of the parish of Saint Félicien, countv of Lake Saint Jolm, TUESDAY, the ELEVENTH day of SEPTEMBER, at TEN o'clock in the forenoon.CEO.LEVESQUE, Sheriff.Sheriff's office.Roberval, 7th August.1917.3754\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917.] CURATOR'S WARRANT.Superior Couri.Province of Quebec, \\ IN the matter of J.-District of Roberval, J * ARTHUR GUE-Xo.1122.' RIN, merchant, of Saint-Jérôme, insolvent ; and CHS-\\.SYLVESTRE, curator, to wit.1.A two stoiy furniture store measuring aDOUt thirty feet in width by eighty feet in length, erected on the south half of the lot of land known and designated under the number forty-six-B-thirty three (South !^ 46fc-83), of the official cadastre for the first range of the township Caron, measuring about forty feet in front by about eighty six feet in depth; bounded in front towards the west by the public road, in the rear towards the east by the lot number forty-six-B-thirty-seven, adjoining on the north the land of Frédéric Thibault, and on the south the emplacement of Honoré Bilodeau ; 2.The south half of the lot of land known and designated under the number forty-six-B-thirty-four (South Yi 466-34), of the official cadastre for the said first range of the township Caron\u2014 with the buildings thereon erected; the said land measuring about forty feet in front by eighty seven feet in depth ; bounded in front towards the west by the public road, in the rear towards the east by the lot number forty-six-B-tliirty-seven, adjoining on the north the emplacement of Honoré Bilodeau, and on the south the emplacement of Stanislas Fortin ; 3.A lot of land measuring about one hundred and sixty feet in front by ninety five feet in depth, forming part of the lot of land known and designated under the number forty-six-B-thirty-scven (Part 466-37), of the official cadastre for the said first range of the township Caron, in the county of Lake Saint-John\u2014with a garage thereon erected, of twenty feet by twenty five feet ; bounded on the east by the land of André Néron, on the west partly by the land of Frédéric Thibault, partly by the two lots of land herealx>ve descrilxîd and partly by the land of Honoré Bilodeau.adjoining on the north the land of Joseph lefebvre or representatives, and on the south the land of Stanislas Fortin.To be sold at the church door of the parish of Sainte-Jérôme, (Métabetchouan), lake Saint John, on WEDNESDAY, the TWELFTH day of SEPTEMBER, 1917, at ELEVEN o'clock in the forenoon.*\"< GEO.LEVESQUE, jr ' Sheriff.Sheriff's office.'\"T Roberval, 7th August, 1917.3772\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917.] 2076 TERREBONNE TERREBONNE FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Cour supérieure.District de Terrebo-ime,\\ I A SOCIETE No891./ D'ADMINIS- TRATION GENERALE, demanderesse, ès-qual.; vs LOUIS RIOPEL, fils de Maxime, défendeur, savoir : Un terrain étant partie du lot numéro vingt-huit (28), du neuvième rang du canton Wexford, paroisse de Sainte-Marguerite, comté et district de Terrebonne, aux plan et livre de renvoi officiels faits pour ladite paroisse, situé h i>eu près à quatre ou cinq arpents du cordon entre le dixième et le neuvième rang de Wexford, contenant un arpent et demi de largeur sur la profondeur comprise entre le chemin public et la première branche du bras est, tenant des deux côtés au reste dudit No.28\u2014avec moulin à scie et autres bâtisses dessus et tous les droits au pouvoir d'eau sur lequel se trouve ledit moulin, comprenant les tournants, mouvants et autres accessoires dudit moulin.Pour être vendu à la porte de l'église catholique du village de Sainte-Marguerite, dit district, le QUATORZIEME jour de SEPTEMBRE prochain 1917, à DEUX heures de l'après-midi.Le shérif, PREVOST & CYR.Bureau du shérif.3775\u201432-2 Samte-Scholastique, 8 août 1917.[Première publication, 11 août 1917.] FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Superior Court.District of Terrebonne,\\ I A SOCIETE No.891.) L« D'ADMINIS- TRATION GENERALE, plaintiff, ès-qual.; vs LOUIS RIOPEL, son of Maxime, defendant, to wit : A lot of land being part of lot number twenty eight (28), of the ninth range of the township of Wexford, parish of Sainte-Marguerite, county and district of Terrebonne, on the official plan and book of reference made for the said parish, situate about four or five arpents from the line between the tenth and the ninth range of Wexford, containing one arpent and a half in width by the depth comprised between the public road and the first branch of the eattt arm, adjoining on both sides the remainder of the said No.28\u2014 with sawmill and other buildings thereon and all rights in the water power on which the said mill is situate, including the equipment of the said mill.To be sold at the catholic church door of the village of Sainte-Marguerite, said district, on the FOURTEENTH day of SEPTEMBER next, 1917, at TWO o'clock in the afternoon.PREVOST & CYR, Sheriff.Sheriff's office.3776\u201432-2 Samte-Scholastique, 8th August, 1917.[First publication, 11th August, 1917.] TROIS-RIVIÈRES FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Cour supérieure.\u2014District des Trois-Rivières.Trois-Rivières, à savoir:! F\\AME VICTORI-No 171.f 1/ NE LAROCHE, demanderesse; vs THEOPHILE POISSON, défendeur.Comme appartenant à ladite demanderesse, Dame Victorine Laroche, veuve de Uldoric Beauchesne, savoir: Un terrain situé à la concession nord-est de la rivière Gent illy, en la paroisse de Gentilly, connu et désigné aux plan el livre de renvoi officiels du cadastre d'enregistrement du comté de Nicolet, pour ladite paroisse de Gentilly, comme étant les numéros quatre cent quarante-deux et quatre cent quarante-trois (Nos 442 et 443), du contenu d'environ deux arpents en superficie, plus ou moins, et sans garantie de mesure précise; prenant en front à la rivière Gentilly, se terminant en profondeur à Albert Toutant ainsi que du côté nord-est, et au sud-ouest à Ferdinand Beauchesne, aussi que sur un chemin de passage pour communiquer dudit No 443 au chemin public.Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de Saint-Edouard-de-Gentilly, le ONZIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à DIX heures du matin.Le shérif, CHAS.DUMOULIN.Bureau du shérif.Trois-Rivières, 3 août 1917.3773\u201432-2 [Première publication, 11 août 1917].THREE RIVERS FIERI FACIAS DE BONIS ET DE TERRIS.Superior court.\u2014District of Three Rivers.Three Rivers, to wit:) iSaME VICTORINE No.171./ LAROCHE, plaintiff; vs THEOPHILE POISSON, defendant.As belonging to the said plaintiff, Dame Victorine Laroche, widow of Uldoric Beauchesne, to wit: A loi of land situate in the northeast concession cf the river Gentilly, in the parish of Gentilly, known and designated on the official plan and book of reference of the registration cadastre of the county ot Nicolet, for the said parish of Gentilly, as being the numbers four hundred and forty two and four hundred and forty three (Nos.442 and 443), containing about two arpents in area, more or less, and without warranty of exact measurement; bounded in front by the river Gentilly, and ending in depth at Albert Toutant and also on the northeast side, and on the southwest by Ferdinand Beauchesne and also on a roadway to communicate from the said No.443 to the public road.To be sold at the church door of the parish of Saint-Edouard-de-Gentilly, on the ELEVENTH day of SEPTEMBER next, at TEN o'clock in the forenoon.CHARLES DUMOULIN, Sheriff.Sheriff's office.Three Rivers, 3rd August, 1917.3774\u201432-2 [First publication, 11th August, 1917]. 2077 Ministère de la colonisation, des Department of Colonization, Mines mines et des pêcheries and Fisheries Ordonnance pour la fermeture de la route située entre les lots Nos 21 et 22 du 2ème rang du canton Taillon et celle entre les lots 26 et 27 des rangs 3 et 4 du même canton, dans le comté du Lac Saint-Jean.Attendu que le conseil municipal de la paroisse de Saint-Henri-de-Taillon, dans le comté du Lac-Saint-Jean, par une résolution en date du ilèine jour du mois de juillet 1917, demande la fermeture de la route située entre les lots Nos 21 et '-'2 du 2ème rang du canton Taillon et de celle située entre les lots Nos 26 et 27 des rangs 3 et 4 du même canton, et que copie de ladite résolution a été déposée dans les archives du ministère de la colonisation, des mines et des pêcheries sous le No 71-220 des lettres reçues pour l'année 1917; Attendu que la raison alléguée à l'appui de la dite demande est que ces routes sont devenues inutiles, vu qu'elles ont été remplacées par d'autres; Attendu qu'il y a lieu d'accéder à cette demande et qu'en vertu de l'article 2065 des Statuts refondus de la province de Québec, 1909, ces routes ne peuvent être fermées sans une autorisation du ministère de la colonisation, des mines et des pêcheries, des deniers du gouvernement y ayant été dépensés ; En conséquence, pour me conformer au désir du conseil municipal de la paroisse de Saint-Henri de-Taillon, dans le comté du Lac Saint-Jean, j'autorise la fermeture des routes plus haut mentionnées et ordonne que les terrains qu'elles occupent, retournent t\\ leurs anciens propriétaires ou successeurs.Le sous-ministre, S.DEFAULT.Québec, 30 août 1917.4047 Ohdeh for closing of the road lying between the lots Nos.21 and 22 of the 2nd range of Taillon township and that between the lots 26 and 27 of ranges 3 and 4 of same township, in the comity of Lake Saint John.Whereas the municipal council of the parish of Saint-Henri-de-Taillon, in the county of Lake-Saint-John, by resolution dateVl the 9th day of the month oi July, 1917, makes application for the closing of the road lying between the lots Nos.21 and 22 of the 2nd range of Taillon township and of that lying between the lots Nos.26 and 27 of ranges 3 and 4 of same township and that a copy of said resolution has been filed in the archives of the Department of Colonization Mines and Fisheries under the No.71-220 of letters received for the year 1917.Whereas the reason set forth in support of said application is that the above roads are no longer of any use having been replaced by others; Whereas there is sufficient cause to grant this application and that under article 2065 of the Revised statutes of the province ot Quebec, 1909, these roads cannot be closed without an order from the Department of Colonization, Mines and Fisheries.Govennent monies having been expended thereon.In consequence, to comply with the desire of the municipal council of the parish of Saint-Henri de Taillon in the county of Lake Saint-John.I do authorize the closing of the above mentioned roads and order that the ground they occupy revert to their former proprietors or successors.S.DUFAULT, Deputv Minister.Quebec, 30th August, 1917.* 4048 ERRATUM A la page 1922 de la \"Gazette officielle du vingt-cinq août 1917, aux numéros 3913-14, lisez: Donné en Notre, etc., en date du 24ème jour d'août au lieu de septembre.4049 Faillite ERRATUM On page 1922 of the \"Official Gazette\" of the twenty fifth day of August, 1917, numbers 3913-14, read: given at Our, etc., this twenty fourth day of August, instead of September.4050 Bankruptcy Province de Québec, district de Beauharnois.Cour supérieure.In re : Pierre-S.Ostiguy, Salaberry-de-Valley field, Que.Avis est donné par la présente que le 23ème jour d'août 1917, lesoussigné a été nommé, par une ordonnance de la cour, curateur en cette affaire.Les créanciers dudit insolvable sont requis de filer leurs réclamations à mon bureau, 83 rue Craig-Ouest, Montréal, sous trente jours du présent avis, s'ils ne l'ont déjà fait.Le curateur, VINCENT LAMARRE.Bureaux : 820 édifice \"Power\".Montréal, 27 août 1917.4001 Province of Quebec, district of Beauharnois.Superior Court.In re : Pierre-S.Ostiguy, Salaberry-de-Valleyfield, Que.Notice is hereby given that on the 23rd day of August, 1917, the undersigned has been appointed curator, by an ordonnance of this Court, to the above estate.Creditors of the said insolvent are required to fyle their claim at my office, 83 Craig street West, Montreal, if they have not already done so, within thirty days from the date of present notice.VINCENT LAMARRE, Curator.Office: 820 \"Power\" bldg.Montreal, 27th August, 1917.4002 2078 Province de Québec, district de Montcalm.Cour supérieure.In re: Dame Georges Barrette, Rapide-de-l'Orignal, Que., insolvable.Un premier bordereau de dividende a été préparé en cette affaire et sera ouvert à objection jusqu'au 15 septembre, 1917, après laquelle date ce dividende sera payable à mon bureau, 83 rue Craig-Ouest, Montréal.I^e curateur, VINCENT LAMARRE.Bureaux : 820 édifice \"Power\".Montréal, 29 août 1917.3999 Province de Québec, district de Montréal.Dans l'affaire de: Rosemount Hardware, Montr réal.Avis est par le présent donné qu'un premier dividende a été déclaré et sera payable à notre bureau, lundi, le 17 septembre 1917.Toute contestation doit être déposée entre nos mains avant la date susmentionnée.TURCOTTE & MERRILL.97, rue St-Jacques, Montréal.4003 Re : Zéphirin Ixdièvre, de Petite-Rivière-Est.marchand, insolvable.Avis est par le présent donné qu'en vertu d'un jugement de la cour suj)érieure pour le district de Bonaventure, en date du 29 août 1917, les soussignés ont été nommés curateurs conjoints.Les créanciers dudit insolvable sont requis de nous produire leurs réclamations dans les trente jours de cette date.Les curateurs conjoints, LEFAIVRE & GAGNON.Bureaux : 147 Côte de la Montagne, (Edifice Bossé).Québec, 29 août 1917.4005 Canada, province de Québec, district de Beauce.Cour supérieure.In re: Frs.Bolduc, enrg.Beauceville, insolvable.En vertu d'un ordre de la cour, en date du 24 août 1917, j'ai été nommé curateur aux biens de cette faillite.Toutes personnes ayant des réclamations contre cette faillite sont requises de les produire devant moi dans les trente jours de cette date.Le curateur, J.-P.-E.GAGNON.Bureaux: 44 et 46 rue Dalhousie.Bâtisse de la Canada Steamship Lines, Ltd.Québec.29 août 1917.4007 Province de Québec, district d'Iberville.Cour supérieure.In re: Pierre Auclair, marchand de fruits, de la cité de Saint-Jean.Avis est donné que le vingt-cinq août courant 1917, ledit Pierre Auclair a déposé son bilan et fait cession de ses biens, et le soussigné a été nommé gardien provisoire de tous les biens abandonnés par le failli.Le gardien provisoire.J.-AIME LUSSIER, notaire.Daté à Saint-Jean, ce 29 août 1917.4009 Province of Quebec, district of Montcalm.Superior Court.In re* Mrs.Georges Barrette] Raipidc-de-1'Orignal, Que., insolvent.A first dividend sheet lifts been prepared in this matter and will l>e open to objection until 15th September, 1917, after which date this dividend will be payable at my office, 83 Craig street West, Montreal.VINCENT LAMARRE, Curator.Office: H20 \"Power\" bldg.Montreal.29th August, 1917.4000 Province of Quebec, district of Montreal.In the matter of: Rosemount Hardware, Montreal.Notice is hereby given that a first dividend has been declared and will be paid at our office, on Monday, the 17th day of September, 1917.Any contestation must be deposited with us before the date above mentioned.TURCOTTE & MERRILL, 97 Saint James street, Montreal.4004 Re: Zéphirin Lelièvre, of Little-River-Hast, merchant, insolvent.Notice is hereby given that in virtue of a judgment of the Superior Court, for the district of Bonaventure, dated 29th August, 1917.the undersigned have been appointed joint curator.-.The creditors of the said insolvent are requested to fyle us their claims within thirty days from this date.LEFAIVRE & GAGNON, Joint curators.Offices: 147 Mountain Hill, (Bossé building).Quebec, 29th August, 1917.4000 Canada, Province of Quebec, district of Beauce.Superior Court.In re: Frs.Bolduc, enrg., Beauceville, insolvent.In virtue of an order of the Court, dated 24th August, 1917, I have been appointed curator to this estate.All persons having claims against this estate are requested to file them with me within thirty days from this date.J.-P.-E.GAGNON, Curator.Office: 44 & 46 Dalhousie street., Canada Steamship Lines, Ltd., bldg.Quebec, 29th August, 1917.400S Province of Quebec, district of Iberville.Superior Court.IA re: Pierre Auclair, fruit merchant, of the city of Saint Johns, insolvent.Public notice is hereby given that on the 25th instant, 1917, the said insolvent Pierre Auclair, has made an abandonment of his real estate and properties, and the undersigned, notary, of the city of Saint Johns, has been appointed provisory guardian to his estate.J.-AIME LUSSIER, notary.Provisory guardian.Given at Saint Johns, this 29th day of August, 1917.4010 2079 Nombre de directeurs diminué Number of directors decreased Avis: Nombre des directeurs diminué de cinq a Notice: of decrease of directors from five to trois.three.Règlement No 11.By-Law II.(«) Bureau des directeurs et quorum.(«) Board of directors and quorum.Les affaires de la compagnie, nonobstant la The affairs of the company, notwithstanding claUM de hi charte de la corporation pourvoyant the provision in the Company's Charter appoiut- ;'i la nomination de cinq directeurs provisoires, ing five provisional directors, shall he manuged by seront administrées par un conseil de trois direc- a board of three directors of whom two shall form teurs.dont deux formeront le quorum nécessaire a quorum for the transaction of business, à l'expédition des affaires.Les règlements de la compagnie, adoptés à The by-laws of the company enacted by the l'assemblée des directeurs tenue le S août 1917.meeting of directors held on the 8th day of ont 'été expressément ratifiés, confirmés et August, 1917.were specially ratified, confirmed approuvés, y compris le règlement par lequel aim approved, including the by-law changing le nombre des directeurs est changé de cinq à the number of directors from five to three, t rois.Je.Edgar-J.Cleaver, secrétaire-trésorier de la (dove & Mitt Company of Canada, Limited\", certifie par les présentes que le premier des extraits précités est une copie conforme du reniement 11, sous-section («) des règlements de la \"Glove & Mitt Company of Canada.Limited\", et que le deuxième extrait provient d'une résolution adoptée à une assemblée générale spéciale des actionnaires de cette corporation, tenue le 8 août 1917.Le secrétaire-trésorier.E.-J.CLEAVER.Copie conforme.Les procureurs de la \"Glove & Mitt Co.of Canada.Ltd.\" CAMPBELL.McMASTER & PAPINEAU.Montréal.17 août 1917.4045 I, Edgar-J.Cleaver, the Secretary-treasurer of the Clove & Mitt Company of Canada.Limited, do hereby certify that the first of the foregoing extracts is a true copy of by-law II.sub-section (c) of the by-laws of the Clove and Mitt Company of Canada.Limited, and that the second extract is that of a resolution passed at a special general meeting of the shareholders of that company, held on the 8th day of August.1917.E.-J.CLEAVER.Secretary-treasurer.True copy.CAMPBELL.M cM ASTER & PAPINEAU.Attorneys for Glove & Mitt Company of Canada, Limited.Montreal.17th August.1917.4046 Requête de notaire Notary's application Avis est par le présent donné, conformément aux dispositions du Code du notariat, qu'une requête a été présentée par M.J.-Arthur Pérodeau, notaire,.de la cité de Montréal, par laquelle il demande le transfert en sa faveur des minutes, répertoires et index des feus Francis-Ethelbert McKenna, Ernest-Henry Stuart et William-Henry Cox, en leur vivant notaires, de ladite cité de Montréal.3605\u201431-5 Notice is hereby given, pursuant to the provisions of the notarial Code, that application is made by Mr.J.-Arthur Pérodeau, notary, of the city of Montreal, for the transfer, in his favor, of the minutes, repertory and index of the late Francis-Ethelbert McKenna, Ernest-Henry Stuart and William-Henry Cox, in their lifetime notaries, of said city of Montreal.3606\u201431-5 Ventes de Faillite Insolvent Sales Province de Québec, district de Bedford.Cour supérieure.No 261.Dans l'affaire de Albert Pontbriand, de Roxton-Falls, failli.Avis est r)ar le présent donné que agissant sous l'autorité donnée par un jugement de la cour supérieure, les soussignés vendront par encan public les immeubles suivants: 1.Un terrain sis et situé au village de Roxton-Falls, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels pour ledit village de Roxton-Falls, sous le numéro trois cent soixante-treize (373)\u2014avec les bâtisses y érigées ; 2.Un autre terrain sis et situé au village de Sainte-Pudentienne, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels pour le dit village de Sainte-Pudentienne, sous le numéro vingt-neuf-vingt-deux (29-22) \u2014 avec les bâtisses y érigées; Province of Quebec, district of Bedford.Superior Court, No.261.In the matter of: Albert Pontbriand, of Roxton-Falls, insolvent.Notice is hereby given that acting under the authority given by a judgment of the Superior Court, me Undersigned will sell by public auction the following immoveables : 1.A piece of land situated in the village of Roxton-Falls, known and designated upon the official plan and book of reference for the said village of Roxton-Falls, under number three hundred and seventy three (373)\u2014with the buildings thereon erected ; 2.Another piece of land situated in the village of Sainte Pudentienne, known and designated upon the official plan and book of reference for the said village of Sainte Pudentienne, under number twenty nine-twenty two (29-22) \u2014 with the buildings thereon erected ; 10 2080 3.Une balance de prix de vente au montant de deux mille cinq cent cinquante-cinq piastres ($2,555) due par Télesphore Brodeur, de Roxton sud, en vertu d'un acte de vente â lui consenti par Albert Pontbriand, en date du 10 octobre 1913, devant Jos.-H.Marcoux, notaire; ladite somme de deux mille cinq cent cinquante-cinq piastres payable cent piastres par année, avec intérêt au taux de cinq pour cent par an à partir du premier novembre mil neuf cent seize, et portant hypothèque sur le terrain suivant :\u2014\"Un terrain connu et désigné comme faisant partie des lots numéro neuf \"B\" et dix \"A\" sur les plan et au livre de renvoi officiels du troisième rang du canton de Roxton.La vente dudit terrain portant le numéro trois cent soixante-treize (373) du cadastre de Roxton-Falls, aura lieu à la porte de l'église paroissiale de Saint-Jean-Baptiste-de-Roxton, VENDREDI, le VINGT ET UNIEME jour deSEPTEMBRE prochain (1917), à UNE heure de l'après-midi; et la vente du terrain portant le numéro vingt-neuf-vingt-deux (29-22) du cadastre de Sainte-Pudentienne, et celle de ladite balance de prix de vente, savoir deux mille cinq cent cinquante-cinq piastres, auront lieu à la porte de l'église paroissiale de Sainte-Pudentienne, SAMEDI le VINGT-DEUXIEME jour de SEPTEMBRE prochain (1917).à DEUX heures de l'après-midi.Conditions : argent comptant.Donné au village de Roxton-Falls, ce vingt-neuvième jour du mois d'août mil neuf cent dix-sept.Les curateurs conjoints, L.TRANCHEMONTAGNE.& J.RAICHE.Bureau: L.Tranchemontagne, N.P., Roxton-Falls, Que.4011 Canada, Cour supérieure, province de Québec, district de Québec, No 1086.Dans l'affaire de: Auxilia Therrien, faisant affaire sous la raison sociale \"Ed.Cauchon & Cie\", entrepreneurs menuisiers, Québec, insolvable.Avis est par le présent donné que VENDREDI, le 14 SEPTEMBRE 1917, à 10.30 hrs.A.M., sera vendu par encan public, à notre bureau 52 rue Saint-Joseph, à Québec, l'actif de cette faillite, comme suit: A.\u2014Un lot de bois suivant inventaire.$79.20 Ameublement de la boutique.10.25 -$ 89.45 B.\u2014Outillage suivant liste.201.20 C.\u2014Un terrain mesurant environ 37^6 pieds de front par 50 de profondeur plus ou moins\u2014 avec maison dessus construite, située au No 84 avenue Lamontagne, domaine Lairet, à Québec, étant la moitié des lots 411Â- et 41 il du cadastre officiel pom* Saint-Roch-Nord\u2014avec circonstances et dépendances, sujet à une rente annuelle et constituée de $12.00 payable le 1er de mai de chaque année à M.M.Landry & Belleau, tel que décrit à l'acte de vente à constitution de rente par A.-C.-P.-R.Landry et I.-N.Belleau à Dame Auxilia Therrien, le 21 de mars 1911, devant J.-E.Plamondon, N.P., sous le No 6441.D.\u2014Les droits que peut posséder le failli sur une bâtisse construite sur le lot 411/ du cadastre officiel pour Saint-Roch-Nord, située en arrière de la moitié des terrains ci-haut décrits et servant de boutique de menuisier.E.\u2014Un terrain mesurant environ 37^ pieds de front par 50 de profondeur, plus ou moins avec maison dessus construite, située aux Nos 3.A certain balance of a price of sale amounting to two thousand five hundred and fifty-five dollars ($2,555) due by Télesphore Brodeur.of South Roxton, by and in virtue of a deed of sale to him consented by Albert Pontbriand on the sixteenth day of October, 1913, before Jos.-M.Marcoux, notary; the said sum of two thousand five hundred and fifty five dollars payable in yearly payments of one hundred dollars each, with interest at the rate of five per cent per annum from the first day of Novemlier, 1916, and being hypothecated on the following immoveable: \"A piece of land known and designated as forming part of lots nine \"B\" and ten \"A\", on the official plan and book of reference ol the third range of the township of Roxton.The sale of the said lot 373 will take place at I he parochial church door of Saint-Jean-Baptiste-de-Itoxton, FRIDAY, on the TWENTY FIRST day of SEPTEMBER next (1917), at ONE o'clock in the afternoon; and the sale of loi 29-22 and also the sale of the said balance of two thousand five hundred and fifty five dollani will take place at the church door of the parish of Sainte Pudentienne, SATURDAY, on the TWENTY SECOND day of SEPTEMBER next (1917), at TWO o'clock in the afternoon.Terms of sale: Cash.Given at Roxton-Falls, this twenty ninth day of August, one thousand nine hundred and seventeen.L.TRANCHEMONTAGNE & J.RAICHE.Joint curators.Office: L.Tranchemontagne, N.P., Roxton Falls, Que.4012 Canada, Superior Court, Province of Quebec, district of Quebec, No.1686.In the matter of: Auxilia Therrein, carrying on business under the firm, name and style of \"Ed.Cauchon & Cie\", contractors and joiners, Quebec, insolvents.Notice is hereby given that on FRIDAY, the 14th of SEPTEMBER, 1917, at 10.30 A.AI.there will be sold at our office, 52 Saint Joseph street, at Quebec, the assets of this estate being as follows: A.\u2014A lot of lumber as per inventory.$79.20 Shop equipment.10.25 -1 80.45 B.\u2014Machinery as per list.201.20 C.\u2014A lot of land measuring about S7l/o f^t in front by 50 in depth, more or less\u2014with a house thereon erected, situate at the No.84 Lamontagne Avenue, Domaine Lairet, at Quebec, being the half of the lots 411A; and 41H of the official cadastre for Saint Roch-North\u2014with circumstances and dependencies, subject to an annual constituted ground rent of $12.00 payable on the 1st of May of every year to Messrs Landry & Belleau, as described in a deed of sale with coiistitucd rent by A.-C.-P.-R.Landry and I.-N.Belleau to Dame Auxilia Therrien, on the 21st of March, 1911, before J.-E.Plamondon, N.-P., under the No.6441.D.\u2014All the rights of the insolvent in a building erected on the lot 411j of the official cadastre or Saint Roch-North, situate at the rear of the half of the above described lots and used as a carpenter shop.E.\u2014A lot of land measuring about 97H feet in front by 50 in depth, more or less\u2014with a house thereon erected, bearing Nos.80-82 Lamontange 2081 90-82 avenue I^montagne, domaine Lairet, à Quélrcc, étant la moitié des lots 411*.41 II du ert parish.I!\u2022:;:.Paroisse Saint-Benoit.1936 Saint Benoit parish.1036 Assemblée :\u2014 Meeting :\u2014 La Cie du chemin de fer de la Baie des Ha ! Ha ! Bav Railwav Coy.19-17 Ha ! Ha!.1947 département de l'instruction publique :\u2014 department of public instruction :\u2014 Languedoc.1943 Templcton a-to l'Ange-Gardien.1943 Lots paroisse\u2014parish Leeds à-to Leeds Villemontel.1944 Est-East.1943 Département du trésor (Branche des Treasury department (Insurance Branch) :\u2014 assurances) :\u2014 The Canadian Surety Company.1944 The Canadian Surety Company.1914 Erratum:\u2014 Erratum:\u2014 Page 1922, 25 août, Nos 3913-14.2077 Page 1922, 25th August, Nos 3913-14.2077 Faillite:\u2014 Bankrufcy:\u2014 Auclair.2078 Magnan.1947 Barrette (Dme).2078 Ostiguy.2077 Bolduc.2078 Quévillon.194 s Benoit.1948 Rosemoun, Hardware.207S Brunetti.1948 Vézina.1047 Colville's.1948 Welland Hotel Co., Ltd.194S Lelièvre.2078 LiTTRKs patentes:\u2014 Letters patent:\u2014 The Canadian Skirt & Waist Manufac- The Canadian Skirt & Waist Manufacturing Coy, Ltd.1942 turingCoy, Ld.1942 Ministère de la colonisation, des mines et Department of colonisation, mines and des pêcheries :\u2014 fisheries :\u2014 Saint-Henri-de-Taillon, comté du Lac- Saint-Henri-dc-Taillon, county of Lake Saint-Jean.2077 Saint-John.2077 Nominations :\u2014 An ointments :\u2014 Commissaires d'écoles:\u2014 School commissioners:\u2014 Municipalité de Percé, comté de Gaspé 1943 Municipality of Percé, county of Gaspé 194:5 Municipalité de Saint-Samuel-de-Gay- Municipality of Saint-Samuel-de-Gay- hurst, comté de Frontenac.1943 hurst, county of Frontenac.1943 Municipalité de Saint-David-de-l'Au- Municipality of Saint-David-de-l'Au- berivière, comté de Lévis.1943 berivière, county of Levis.1943 Municipalité de Saint-Germain, comté Municipality of Saint Germain, county de Rimouski.1943 of Rimouski.1943 Municipalité du canton de Loranger, comté de Labelle.1943 Greffier de la cour du Magistrat :\u2014 Saint-Hyacinthe.1935 Proclam ations :\u2014 Féte du Travail\u2014Labor Day.1911 Paroisse\u2014Parish Sainte-Angèle.comté de \u2014county of Maskinongé.1937 Requête de notaire :\u2014 J.-Art.Pérodeau.2079 Ventes de faillite:\u2014 Pontbriand.2079 Vente par licitation:\u2014 Bénard (Dlle) vs Bénard èsql et al.1949 Vente pour taxes municipales:\u2014 La Cité de Montréal vs Divers.1950 VENTES PAR LES SHÉRIFS:\u2014 Bedford:\u2014 Cloutier vs Laprés.2059 Joliette :\u2014 Thériault vs L'Epicier.2000 Montréal:\u2014 Deseheneaux, failli-insolvent.2007 Dugas vs.Lapointc.2070 Handfield vs Pélodeau et al.2070 Hudon vs Dme Coimolly ctal.20(50 Hudon vs Dme Connolly et al.2009 Hudon vs Dme Coimolly et al.2009 KyddvsHope.2061 Gagnon vs Lacoste et al.2062 Gagnier vs Dufresne.2002 La cité de \u2014The city of Lachine vs Wiar- ton Realty Coy, Ltd.2003 Lamarre (Dme) csql.vs Leblanc csql.2060 Ottawa:\u2014 Dufresne, failli-insolvent.2071 La Banque Provincial du Canada vs Sims et al.2071 Québec:\u2014 Montreuil vs Lefebvre.2072 Rimouski :\u2014 ê Bellavance & Cie vs Brisson.2074 Roberval:\u2014 De Laval Dairy Supply Co.Ltd vs Cas-tonguay.2074 Municipality of the township of Granger, county of Labelle.1943 Clerk of the Magistrate's Court:\u2014 Saint Hyacinthe.1935 Proclamations:\u2014 Paroisse\u2014Parish Saint-Mathieu-dc-Rioux comté de-county of Rimouski.1938 Saint-Germain-de-Grantham, comté de\u2014 county of Drummond.1939 Notary's application :\u2014 J.-Art.Pérodeau.2079 Insolvent sales:\u2014 Therrien.2080 Sale by licitation:\u2014 Bénard (Dlle) vs Bénard èsql étal.1949 Sales for municipal taxes:\u2014 The City of Montreal vs Divers.1950 SHERIFFS' SALES:\u2014 Bedford:\u2014 Cloutier vs Laprcs.2059 Joliette :\u2014 Thériault vs L'Epicier.2060 Montreal:\u2014 lies Commissaires d'écoles de la municipalité du\u2014The school Commisioners of the municipality of Coteau Saint Pierre vs Dlle Rapp.2007 Les Conunissaires d'écoles de la municipalité du\u2014The school commissioners of the municipality of Coteau Saint Pierre vs Alexander.2068 Messier et al vs D'Ambrosio.2067 Moqum vs Dme Angrignon.2061 Payette (Dlle) vs Latreille etal.2065 Poirier vs Hurtubise.2060 Rovèsç/vs Tétrault.2068 Sénécal (Dme) vs Dme McGoldrick.2062 Ottawa:\u2014 Roux et al va Bélanger été.2072 Sanscartier vs Kinsbury.2072 Quebec:\u2014 Vermettevs Fortin.2073 Rimouski :\u2014 La Cie Desjardins vs Gagné Capucins.2074 Roberval:\u2014 Guerin, failli-insolvent.2073 2084 Tsrbebonnjb:\u2014 Tibbibomn»:\u2014 le Société d'Administration générale, la Société: d'Administration générale, èeql vs Rjopel.2070
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.