Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 25 février 1950, samedi 25 (no 8)
[" Tome 82, N° 8 - 677 Vol.82, No.8 (Drapeau de la provinoe de Québec, adopté par arrêté en conseil numéro 72, en date du 21 janvier 1948.) (Flag of the Province of Quebec, adopted by order in Council Number 72, bearing date January 21st, 1948.) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) ________ * Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC\tPROVINCE OF QUEBEC Québec, samedi 25 février 1950\tQuebec, Saturday, Februart 25th, 1950 AVIS AUX INTÉRESSÉS\tNOTICE TO INTERESTED PARTIES Règlements\tRules 1° Adresser toute correspondance à: lTmpri- 1.Address all communications to: The King's meur du Roi, Québec.^ Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues .2.Transmit advertising copy in the two officiai officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When same is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at thn frais des intéressés, d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official rates.3° Spécifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions 4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates dant, exception est faite lorsque ces annonces hereinbelow set forth.Exception being made doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé when the said advertising copy is to be published doit alors acquitter la facture sur réception et several times.The interested party shall then avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière pay upon reception of his account and before insertion est suspendue, sans autre avis et sans the second insertion: otherwise this last insertion préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui will be suspended without further notice and rembourse, chaque fois, s'il v a Heu» toute somme without prejudice as regards the rights of the versée en plus.King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are sont strictement payables d'avance.strictly .payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat the King's Printer, by accepted cheque, by bank de banque ou mandat-poste.or postal money order.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Quebec Official Gazetteis published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter.3366 678 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 25 février I960, Tome 82, N° 8 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8Ô Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de.part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agite, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms,-de chiffres, etc!) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $i la douzaine.Abonnement : $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante : Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et |a lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.26439-1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires\" at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rate, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each yersion.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.0 RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.26439-1-52 Lettres patentes Drapeau Frères Ltée Avis est c^pnné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf janvier 1950, constituant en corporation: Georges Drapeau, gérant, Roland-L.Drapeau, voyageur, tous deux de East-Angus, et Roméo Drapeau, comptable, de Sherbrooke, tous du district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants : Faire le commerce d'épicerie, de boucherie, de mercerie, de quincaillerie et de machinerie, sous le nom de \"Drapeau Frères Ltée\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à East-Angus, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général le neuf janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878-o L.DÊSILETS.Letters Patent Drapeau Frères Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January, 1950, incorporating: Georges Drapeau, manager, Roland L.Drapeau, traveller, both of East Angus, and Roméo Drapeau, accountant, of Sherbrooke, all of the judicial district of Saint-Francis, for the following purposes: To carry on business as grocers, butchers, haberdashers, to deal in hardware and machinery, under the name of \"Drapeau Frères Ltée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at East-Angus, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 25th, 1950, Vol.82, No.8 679 Gagnon Transport Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première paf-tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze janvier 1950, constituant en corporation: Wilbrod Bherer C.R., Jacques Juneau et Guy Pouliot, avocats, des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire le transport de marchandises par véhicules-automobiles, sous le nom de \"Gagnon Transport Ltée\", avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le quatorze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878-0 L.DÊSILETS.Gagnon Transport Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of January, 1950, incorporating: Wilbrod Bherer, K.C., Jacques Juneau and Guy Pouliot, advocates, of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the transportation of merchandise by motor vehicle, under the name of \"Gagnon Transport Limitée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General.Gaucher & Fils Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix janvier 1950, constituant en corporation: J.Théo Legault, jr, notaire, Eileen P.Delaney, comptable agréée, et Réjeanne Robert, sténographe, fi lie \"majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de bijoutier, orfèvre, marchand de diamants, monteur de pierres, horloger et artisan en or, sous le nom de \"Gaucher & Fils Limitée'*,* avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878-0 L.DÊSILETS.Hubert Gaucher & Fils Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du onze janvier 1950, constituant en corporation: J.-Théo Legault, notaire, Eileen P.Delaney, comptable agréée, célibataire, et Réjeanne Robert, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de bijoutier, orfèvre, marchand de diamants, monteur de pierres, horloger et artisan en or, sous le nom de \"Hubert Gaucher & Fils Limitée\", avec un capital de $75,000 divisé en 750 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878-0 L.DÊSILETS.J.A.Aubertin Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-nsset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix-sept janvier 1950, constituant en corporation: Gaucher & Fils Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of January, 1950, incorporating: J.Théo.Legault, Jr., notary, Eileen P.Delaney, chartered accountant, and Réjeanne Robert, stenographer, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as jeweller, goldsmith, diamond merchant, stone setter, clock-maker and \"artisan in gold works, under the name of \"Gaucher & Fils Limitée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General.Hubert Gaucher & Fils Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of January, 1950, incorporating: J.Théo.Legault, Jr., notary, Eileen P.Delaney, chartered accountant, spinster, and Réjeanne Robert, stenographer, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as jeweller, goldsmith, diamond merchant, stone setter and artisan in gold works, under the name of \"Hubert Gaucher & Fils Limitée\", with a capital stock of $75,000 divided into 750 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General.J.A.Aubertin Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-risset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventeenth day of January, 1950, incorporating: Aline Déguise, 680 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC,[Quéhec,r26 février I960, Tome 82, N° 8 Aline Déguise, sténographe, fille majeure, de Sorel, Vital Aubertin, menuisier, de Verchères, tous deux du district judiciaire de Richelieu, et Alice Aubertin, institutrice, fille majeure, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir généralement comme constructeurs ou entrepreneurs-constructeurs et faire le commerce de matériaux, sous le nom de \"J.A.Aubertin Ltée\", avec un capital de $25,000 divisé en 250 actions de $100 chacune.1a1 siège social de la compagnie sera à Verchères, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878-0 L.DÊSILETS.J.A.Thibault & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf janvier 1950, constituant en corporation: Joseph-Adolphe Thibault, Martin Thibault, industriels, et Jean Racieot, notaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer sous toutes ses formes l'industrie et le commerce de la glace naturelle ou artificielle et de tous effets, denrées et marchandises se rapportant audit, commerce, sous le nom de \"J.A.Thibault & Fils Ltée\", avec un capital de $100,000 divisé en 1,200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune et en 800 actions communes d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera A Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le neuf janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878-o L.DÊSILETS.La Compagnie de Déblaiement des Chemins d'Hiver de Kamouraska, Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du onze janvier 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Paul-Aimé Michaud, Paul Gagnon, marchands, de Saint-Denis, et Georges Dubé, transport, de Rivière-?Ouelle, ainsi que Paul-A.Michaud, tous du district judiciaire de Kamouraska, pour les objets suivants: Ouvrir la voie publique (route numéro deux (2) seulement) durant les mois d'hiver, surtout le parcours est-ouest du comté de Kamouraska, sous le nom de \"La Compagnie de Déblaiement des Chemins d'Hiver de Kamouraska, Inc.\" Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Rivière-Ouelle, district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général le onze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878-0 L.DÊSILETS.stenographer, spinster, of Sorel, Vital Aubertin, carpenter, of Verchères, both of the judicial district of Richelieu, and Alice Aubertin, teacher, spinster, of the city and district of Montreal, for the following purposes: To act generally as builders and building contractors and deal in building requisites, under the name of \"J.A.Aubertin Ltée\", with a capital stock of $25,000 divided into 250 shares of S100 each.The head office of the company will be at Verchères, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General.J.A.Thibault & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January, 1950, incorporating: Joseph Adolphe Thibault, Martin Thibault, industrialists, and Jean Racicot, notary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on, under all the forms thereof, the business and trade of natural or artificial ice.and to deal in all goods, wares and merchandise, incidental to the said business, under the name of \"J.A.Aubertin & Fils Ltée\" with a capital stock of $100,000 divided into 1200 preferred shares of a par value of $50 each, and 800 common shares of a par value of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General.La Compagnie de Déblaiement des Chemins d'Hiver de Kamouraska, Inc.Notice is hereby given that fonder Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of January, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: Paul-Aimé Michaud, Paul Gagnon, merchants, of Saint-Denis, and Georges Dubé, carrier, of Rivière-Ouclle, and also Paul A.Michaud, all of the judicial district of Kamouraska, for the following purposes: To open the public road (Highway number two (2) only) during the winther months upon the whole course east-west thereof, of the county of Kamouraska, under the name of \"La Compagnie» de Déblaiement des Chemins d'Hiver de Kamouraska, Inc.\" The amount to which the immovable property which the corporation may possess is to be limited is $25,000.The head office of the corporation will be at Rivière-Ouelle, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 25th, 1950, Vol 52, No.8 681 Les Produits Naturels du Saguenay, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix janvier 1950 constituant en corporation: Edmour Boudreault, ingénieur C.N.R., Roland Barriault, cuviste, Ls-Joseph Blanchettè, herboriste, Louis Simard, ouvrier, tous de Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de produits pharmaceutiques, et ce, sujet aux dispositions de la Loi de pharmacie de Québec; de produits de la ferme et.de produits alimentaires, sous le nom de \"Les Produits Naturels du Saguenay, Limitée\", avec un capital de $40,000 divisé en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 1,200 actions ordinaires de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le dix janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 2C87S-0 L.DÊSILETS.Médicolab Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze janvier 1950, constituant en corporation: Germaine «Martinoli, Yvette Perreault, employées de bureau, de la cité d'Outremont, et Henri Marcaurelle, chimiste, de Ville St-Laurent, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer en général dans toutes ses branches la fabrication et la vente de produits chimiques comme marchands de drogues en gros conformément à l'article 59, Ch.267, S.R.Q.1941, la Loi de la Pharmacie, sous le nom de \"Médicolab Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le onze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878-0 L.DÊSILETS.Nova Drug Limited Nova Drug Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf janvier 1950, constituant en corporation: Jacques Janin, industriel, Maurice-P.Leduc, pharmacien-chimiste, Clifford-J.Malone, comptable, tous de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: D'exercer le commerce de pharmacie et tous autres commerces accessoires d'icelui dans toutes leurs branches, sujet aux dispositions de la Loi de pharmacie de Québec, sous le nom de \"Nova Drug Limited\" \u2014 \"Nova Drug Limitée\", avec/ un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1482A, Ste-Catherine Ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le neuf janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878-0 L.DÊSILETS.Les Produits Naturels du Saguenay, Limité» Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of January, 1950, incorporating: Edmour Boudreault, engineer, C.N.R., Roland Barriault, pot man, Ls.Joseph Blanchette, herbalist, Louis Simard, workman, all of Jonquière, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To manufacture jmd deal in pharmaceutical products, and such, in conformity with the provisions of the Quebec Pharmacy Act; deal also in farm products and foodstuffs, under the name of \"Les Produits Naturels du Saguenay, Limitée\", with a capital stock of $40,000 divided into 100 preferred shares of a par value of $100 each, and 1,200 common shares of $25 each.The head office of the company will be at Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General.Médicolab Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Qovcrnor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of January, 1950, incorporating: Germaine Marti-noli, Yvette Perreault, office employees, of the city of Outrcmont, and Henri Marcaurelle, chemist, of \"Ville St-Laurent\" all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on generally in all the branches thereof, the manufacture and sale of chemicals, act as wholesale druggist, pursuant to section 59, Ch.267, R.S.Q.1941, of the Pharmacy Act, under the name of \"Médicolab Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.Th head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General.Nova Drug Limited Nova Drug Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January, 1950, incorporating: Jacques Janin, industrialist, Maurice P.Leduc, druggist-chemist, Clifford J.Malone, accountant, all of the city of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: 1 To carry on the pharmacy business and any other business incidental thereto, in all branches of same, silbject to the provisions of the Quebec Pharmacy Act, under the name of \"Nova Drug Limited\" \u2014 \"Nova Drug Limitée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1482A St.Catherine Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General, 682 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 25 février 1950, Tome 82, N° 8 Paul Collet & Co.Ltd.Paul Collet & Cie Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf janvier 1950, constituant, en corporation: Paul Collet, industriel, de Westmount, Marc Collet, chimiste, Albert Théberge, avocat, Alice Boire, sténographe, fille majeure, tous trois de la cité de Montréal, et José Luis Autolincz, comptable, de Laval-sur-le-Lac, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre par contrat ou autrement des travaux de réfection de biens meubles et immeubles et exercer le commerce de marchandises se rapportant auxdits travaux, sous le nom de \"Paul Collet & Co.Ltd.\",\u2014 \"Paul Collet & Cie Ltée\", avec un capital de $25,000 divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1030, rue Windsor, \"Hôtel Laurentien\", Montiéal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878-0 .L.DÊSILETS.P.Goodman Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres' patentes en date du onze janvier 1950, constituant en corporation: Peter Goodman, marchand, Edward S.Berger, avocat, et Norma Layman, sténographe, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général comme manufacturiers et marchands de vêtements et de har-des, sous le nom de \"P.Goodman Inc.\", avec un capital de $40.000 divisé en 200 actions privilégiées de $100 chacune et en 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878 L.DÊSILETS.Quebec Chibougamau Goldfields Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minièies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze janvier 1950, constituant en corporation: Frank J.Dolan, Robert H.Waddell, comptables, Lottie Pachal, dactylographe, Gerald McTeigue, procureur, et Denyse Paret, dactylographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: * Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais; Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter le sol, la terre, les roches, et les pierres dans le but»d'en extraire des minerais quelconques, donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; et les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de \"Quebec Chibougamau Goldfields Li- Paul Collet & Co.Ltd.Paul Collet & Cie Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January, 1950, incorporating: Paul Collet, industrialist, of Westmount, Marc Collet, chemist, Albert Théberge, advocate, Alice Boire, stenographer, spinster, all three of the city of Montreal, and José Luis Autolinez, accountant, of Laval-su r-le-Lac, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To undertake by contract or otherwise repair works on movable and immovable property, and to deal in merchandise connected with the said works under the name of \"Paul Collet & Co.Ltd.\" \u2014 \" Paul Collet & Cie Ltée\", with a capi-tal stock of $25,000 divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1030 Windsor Street, \"Hôtel Laurentien\", Montréal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General.P.Goodman Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of January, 1950, incorporating: Peter Goodman, merchant, Edward S.Berger, advocate, and Norma Layman, stenographer, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers in wearing apparel and clothing generally, under the name of \"P.Goodman Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 preferred shares of $100 each and 200 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of January, 1950.L.DÊSILETS, v 26878-0 Deputy Attorney General.Quebec Chibougamau Goldfields Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of January, 1950, incorporating: Frank J.Dolan, Robert H.Waddell.accountants, Lottie Pachal, typist, Gerald McTeigue, barrister, and Denyse Paret, typist, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals; Carry on all operations by which the soil, earth, rocks, and stones may,, for the purpose of extracting any minerals, whatsoever, be mined, crushed or treated in any manner, render such minerals merchantable by any means whatsoever; and sell or otherwise dispose thereof, under the name of \"Quebec Chibougamau Goldfields Limited\", (No Personal Liability), with a capital stock of QUEBEC OFF it! I AL GAZETTE, Quebec, February 25th 1950, Vol.82, No.8 683 mited\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de $3,500,000 divisé en 3,500,000 actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix, payé ou convenu de payer à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878 L.DÊSILETS.Services de Secrétariat Inc.Secretarial Services Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze janvier 1950, constituant en corporation: Georges Bilodeau, avocat, de Westmount, Cécile Bourdon, comptable, et Gilberte Chabot, sténographe, filles majeures, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Organiser et fournir un service général de secrétariat, sous le nom de \"Services de Secrétariat Inc.\" \u2014 \"Secretarial Services Inc.\", avec un capital de $5,000 divisé en 50 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal-Sud, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le douze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 2GS78-0 L.DÊSILETS.Sim-Art Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze janvier 1950, constituant en corporation: Lucien Hamel, publiciste, Germain Simard et Maurice Simard, industriels, ces deux derniers de Ste-Julienne, district judiciaire de Joliette, et le premier des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes et genres d'enseignes, affiches, structures, appareils ou objets relatifs à l'art de la publicité, sous le nom de \"Sim-Art Inc.\", avec un capital de $30,000 divisé en 120 actions ordinaires de $25 chacune et en 270 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Stc-Ju-lienne, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général'le onze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878-0 L.DÊSILETS.$3,500,000 divided into 3,500,00 shares of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal liability in excess of the price paid or agreed to paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of January, 1950.L.DÊSILETS, 20878-o Deputy Attorney General.Services de Secrétariat Inc.Secretarial Services Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of January, 1950, incorporating: Georges Bilodeau, advocate, of Westmount, Cécile Bourdon,, accountant, and Gilberte Chabot, stenographer, spinsters, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To organize and furnish a general secretarial service, under the name of \"Services de Secrétariat Inc.\" \u2014 \"Secretarial Services Inc.\" with a capital stock of $5,000 divided into 50 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal-South, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of Januarv, 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General.Sim-Art Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of January, 1950, incorporating: Lucien Hamel, publicist, Germain Simard and Maurice Simard, industrialists, the two latter of Ste-Julienne, judicial district of Joliette, and the first one of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds and sorts of signs, posters, structures, apparatus or objects relating to the art of publicity, under the name of \"Sim-Art Inc.\", with a capital stock of $30,000 divided into 120 common shares of $25 each and 270 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Ste-Julienne, judicial d'stict of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General.Torsel Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze janvier 1950, constituant en corporation: Henry Maurice Goldberg, manufacturier, Irène Kaplan Goldberg, épouse séparée de biens de Henry Maurice Goldberg, Leonard Goldberg, étudiant, et Maurice H.Sorkin, comptable, tous Torsel Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by fhe Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of January, 1950, incorporating: Henry Maurice Goldberg, manufacturer, Irène Caplan Goldberg, wife separate as to property of Henry Maurice Goldberg, Leonard Goldberg, student, and Maurice H.Sorkin, accountant, all of the city and 684 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 86 février 1060, Tome 82, N° 8 des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Manufacturer et faire le commerce de vêtements de toute description, sous le nom de \"Tor-sel Corporation\", avec un capital de $75,000 divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la-compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878 L.DÊSILETS.judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel of every description, under the name of \"Torsel Corporation\", with a capital stock of $75,000 divided into 400 common shares of a par value of $100.each, and 350 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878-0 Deputy Attorney General.Urban Hotel Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze janvier 1950, constituant en corporation: Raphael Maurice Phillips, ingénieur, Samuel J.Smiley, avocat, et Edmée Lavigne, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce comme hôteliers, sous le nom de \"Urban Hotel Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878 L.DÊSILETS.Urban Hotel Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of January, 1950, incorporating: Raphael Maurice Phillips, engineer, Samuel J.Smiley, advocate, and Edmée jLavigne, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of hotel keepers, under the name of \"Urban Hotel Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, .this eleventh day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878-0 .Deputy Attorney General.Vox Campari i I is Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize janvier 1950, constituant en corporation: Maurice Mercier, avocat, Bertrande Bertrand et Carmen Geoffroy, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de tous appareils électroniques et de tous appareils ou accessoires se rapportant à l'éclairage, le chauffage, la radiotélévision et l'acoustique, sous le nom de \"Vox Campanilis Limitée\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 200 actions sans valeur ou pair ou nominale et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $1,000.Le siège social de la compagnie sera à 4044 est, rue Ontario, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le seize janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 26878-0 L.DÊSILETS.Vox Campanilis Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of January, 1950, incorporating: Maurice Mercier, advocate, Bertrande Bertrand, and Carmen Geoffroy, secretaries, spinsters, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all electronic apparatus and accessories concerning lighting, heating, radiotélévision, and acoustics, under the name of \"Vox Campanilis Limitée\".The capital stock of the company will be divided into 200 shares without par or nominal value, and the amount of capital stock with which the company will begin its operations is $1,000.The head office of the company will be at 4044 Ontario Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878 Deputy Attorney General.Yared's Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf janvier 1950, constituant en corporation: Charles H.Desjardins, Edward G.Tannage, avocats, Jeannette Desjardins, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Yared's Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies* Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of Januaray, 1950, incorporating: Charles H.Des-jardins, Edward G.Tannage, advocates, Jeannette Desjardins, stenographer, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 25th, 1950, Vol.82, No.8 - 685 Posséder, exploiter et exercer tous ou aucun des commerces de marchandises sèches et nouveautés, sous le nom de \"Yared's Limited\", avec un capital de $60,000 divisé en 100 actions privilégiées de $100 chacune et en 500 actions ordinaires de $100 chacune.Ijc siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 20878 L.DÊSILETS.Demandes à là Législature Avis public est par les présentes donné que \"L'Action Sociale Catholique\", corporation constituée par acte de la Législature de la Province de Québec, et dont le siège social est en la cité de Québec, dans le district de Québec, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa prochaine session, pour obtenir une loi augmentant la valeur annuelle des biens immeubles que la corporation est autorisée à acquérir et posséder en cette province et autres fins.< % Québec, le 31 janvier 1950.Le Procureur de L'Action Sociale Catholique, 20767-5-4-o \u2022 GUY HUDON.AVIS Avis est, par les présentes, donné que la \"Montreal City & District Savings Bank \" présentera une,requête demandant la passation d'un bill privé à la prochaine session de la Législature de la province de Québec, afin de déclarer la \"Montreal City & District Savings Bank \" propriétaire entière et exclusive de la propriété ci-après décrite comprenant tous ses membres et appartenances et tous les droits s'y rapportant, à savoir: Ces certaines ruelles plus amplement connues et décrites comme suit : a) Le lot treize cent quarante A (1340A) des plan et livre de renvoi officiels du quartier St-Antoine de ladite cité, mesurant dix-huit pieds de largeur par deux cent douze pieds de longueur et une superficie de trois mille huit cent-seize pieds carrés, toute mesure anglaise et plus ou moins, et borné à une extrémité au sud-ouest par l'avenue McGill College, à l'autre extrémité au nord-est par la rue Victoria, d'un côté au sud-est par les lots treize cent quarante et un, treize cent quarante-deux et treize cent quarante-trois (1311, 1342 et 1343) audit plan officiel et de l'autre côté au nord-ouest par les lots treize cent trente-sept et treize cent quarante (1337 et 1340) audit plan officiel et par la ruelle ci-après mentionnée connue comme étant le lot treize cent quarante B (1340B) audit plan officiel; b) Le lot treize cent quarante B (1340B) aux-dits plan et livre de renvoi officiels mesurant dix-huit pieds et trois pouces de largeur à son extrémité sud-est, dix-huit pieds à son extrémité nord-ouest par cent-cinq pieds et onze pouces de profondeur et une superficie,de mille neuf cent dix-neuf pieds carrés, toute mesure anglaise et plus ou moins et borné à une extrémité au sud-est par la ruelle décrite ci-dessus, à l'autre extrémité au nord-ouest par une autre ruelle ci-après décrite, d'un côté au sud-ouest par une partie du lot To own, operate and carry on all or any of the businesses of dry goods and novelty stores, under the name of \"Yared's Limited\", with a capital stock of $60,000 divided into 100 preferred shares of $100 each, and 500 common shares of $100 each The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorpey General, this ninth day of January, 1950.L.DÊSILETS, 26878-0 Deputy Attorney General.Applications to Legislature Public notice is hereby given that \"L'Action Sociale Catholique\" incorporated by Special Act of the Legislature of the Province of Quebec, and having its head office in Quebec City, in the District of Quebec, will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its next session for the passing of a Special Act increasing the annual value of the immoveable property.which the corporation is authorized to acquire and hold in this Province, and for other purposes.Quebec, this 31st.day of January 1950.GUY HUDON, Attorney for 26767-5-4-0 L'Action Sociale Catholique.NOTICE Notice is hereby given that à Petition for the introduction of a Private Bill will be presented by the Montreal City & District Savings Bank at the forthcoming session of the Legislature of.the Province of Quebec for the purpose of causing the Montreal City & District Savings Bank to be declared the full and exclusive owner of the property hereinafter described including all its Members and Appurtenances and all rights thereto, that is to say: Those certain lanes more fully known and described as: a) Lot thirteen hundred and forty A (1340A) on the official plan and book of reference of the St.Antoine Ward of the said city containing eighteen feet in width by two hundred and twelve feet in lenght and a superficial area of three thousand eight hundred and sixteen square feet all English measure and more or less, and bounded at one end to the south-west by McGill College Avenue, at the other end to the northeast by Victoria Street, on one side to the southeast by lots thirteen hundred and forty-one, thirteen hundred and forty^two and thirteen hundred and forty-three (1341, 1342 and 1343) on the said official plan and on the other side to the north-west by lots thirteen hundred and thirty-seven and thirteen hundred and forty (1337 and 1340) on the siad official plan and by the lane hereinafter mentioned known as lot thirteen hundred and forty B (1340B) on the said official plan; b) Lot thirteen hundred and forty B (1340B) on the said official plan and book of reference containing eighteen feet three inches in width at its south-east end, eighteen feet at its northwest end by one hundred and five feet eleven inches in depth and a superficy of one thousand nine hundred' and nineteen square feet all English measure and more or less and bounded at one end to the southeast by the lane above described, at the other end to the north-west by another lane hereinafter described, on one side 686 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 25 février 1950, Tome 82, N° 8 treize cent trente-quatre et les lots treize cent trente-cinq, treize cent trente-six et treize cent trente-sept (ptie 1334, 1335, 1336 et 1337) audit plan officiel et de l'autre côté au nord-est par ledit lot treize cent quarante et par les subdivisions du lot treize cent trente-neuf (1339) audit plan officiel ; et c) Une ruelle ne portant pas de numéro cadastral mesurant dix-huit pieds de largeur par deux cent trente-six pieds et dix pouces de profondeur et une superficie de quatre mille deux cent soixante-trois pieds carrés, toute mesure anglaise et plus ou moins, et bornée à une extrémité au nord-ouest par la Place Burnside, à l'autre extrémité au sud-est par la ruelle connue comme étant le lot treize cent quarante B (1340B) audit plan officiel et décrit ci-dessus, d'un côté au sud-ouest par les lots treize cent vingt-six, treize cent vingt-sept, treize cent vingt-huit, treize cent vingt-neuf, treize cent trente, treize cent trente et un, treize cent trente-deux, treize cent trente-trois et treize cent trente-quatre (1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333 et 1334) audit plan officiel et de l'autre côté au nord-est par le lot treize cent trente-huit (1338) et les subdivisions dudit lot treize cent trente-neuf (1339) audit plan officiel.libres et claires d'aucun et tous droits, réclamations, charges, privilèges, hypothèques ou encombrements, déclarant lesdites ruelles comme étant et ont toujours été des ruelles privées et autorisant la fermeture de la ruelle connue et décrite ci-dessus comme étant le lot N0 1340A aux-dits plan et livre de renvoi et la partie la plus au sud 36' du lot connu et décrit ci-dessus comme étant le lot N° 1340B auxdits plan et livre de renvoi et pour d'autres fins se rapportant au précédent.Donné en la cité de Montréal, le 1er février 1950.Montreal City & District Savings Bank, Par les Procureurs de la Requérante, 26776-5-4 Hackett, Mulvena & Hackett.AVIS Avis est par les présentes donné que la Ville d'East Angus s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à sa prochaine session, pour obtenir la passation d'une loi amendant sa charte, la loi 2, George V, ch.72, et les différents statuts qui l'amendent, sur les matières suivantes: autoriser la corporation à fixer l'évaluation des compagnies Continental Paper Products et Angus Paper Products à $35,000.00 pour la période du 1er janvier 1950, au 1er septembre 1960, tant au point de vue de taxation municipale que scolaire; autoriser la corporation à fixer l'évaluation de toute ligne électrique parcourant la municipalité, sauf la ligne télégraphique qui longe la voie ferrée du Quebec Central et celles qui appartiennent à la Brompton Pulp & Paper Co.Ltd.à $2,000.00 du mille linéaire; permettre à la corporation, au cas d'incendie, de contracter par règlement non soumis à l'approbation des électeurs propriétaires un emprunt d'au plus $40,000.00, pour régler toute réclamation découlant de la responsabilité civile de ladite corporation, le tout sujet à l'approbation du Ministre des Affaires municipales; et pour autres fins.Sherbrooke, ce 28 janvier 1950.Les Procureurs de la requérante, 26731-5-4-o COTÉ & CRÊPEAU.to the south-west by part of lot thirteen hundred and thirty-four, and lots thirteen hundred and thirty-five, thirteen hundred and thirty-six and thirteen hundred and thirty-seven (pt.1334, 1335, 1336 and 1337) on the official plan and on the other side to the north-east by the said lot thirteen hundred and forty and by subdivisions of lot thirteen hundred and thirty-nine (1339) on the said official plan; and c) A lane bearing no cadastral number, containing eighteen feet in width by two hundred and thirty-six feet ten inches in depth and a superficial area of four thousand two hundred and sixty-three square feet all English measure and more or less and bounded at one end to the northwest by Burnside Place, at the other end to the south-east by the lane known as lot thirteen hundred and forty B (1340B) on the official plan and above described, on one side to the south-west by lots thirteen hundred and twenty-six, thirteen hundred and twenty-seven, thirty hundred and twenty-eight, thirteen hundred and twenty-nine, thirteen hundred and thirty, thirteen hundred and.thirty-one, thirteen hundred and thirty-two, thirteen hundred and thirty-three and thirteen hundred and thirty-four (1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333 and 1334) on the said official plah'and on the other side to the north-east by lot thirteen hundred and thirty-eight (1338) and subdivisions of the said lot thirteen hundred and thirty-nine (1339) on the said official plan, free and clear of any and all rights, claims, charges, privileges, hypothecs or encumbrances, declaring the said lanes to be and always have been private lanes and authorizing the closing of the lane known and hereinabove described as being lot No.1340A on the aforesaid plan and book of reference and the southernmost 36' of the lot known and above described as lot No.1340B on the official plan and book of reference and for other purposes relating to the foregoing.< Given at the city of Montreal this 1st day of February, 1950.Montreal City & District Savings Bank, per: Hackett, Mulvena & Hackett, 26776-5-4-o Attorneys for Applicant.SOTICE Notice is hereby given that the Town of East Angus will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session for the passing of an act amending its charter, the act 2 George V, ch.72, and the various statutes amending it: to authorize the Corporation to fix the valuation of the companies Continental Paper Products and Angus Paper Products to the sum of $35,-000.00 for the pericd starting the 1st of January, 1950 and ending the 1st of September, 1960, such valuation for municipal and school tax purposes; to authorize the Corporation to fix the valuation of all electrical lines running through the Municipality, except the telegraphic line running along side the Quebec Central track and those belonging to the Brompton Pulp & Paper Company Limited to the sum of $2,000.00 for each linear mile; to allow the Corporation in case of fire to contract by a bylaw not subject to the approval of the electors proprietors a loan not exceeding $40,000.CO to settle all claims due to the civil responsibility of the said Corporation, the whole subject to the approval of the Minister of the Municipal Affairs: and for other purposes.Sherbrooke, January 28th, 1950.COTÉ & CREPEAU, 26731-5-4-0 Attorneys of petitioner. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 25th, 1950, Vol.82, No.8 687 AVIS NOTICE Avis est, par les présentes, donné que \"La Lé- Notice is hereby given that \"Canadian gion Canadienne de la Ligue des Anciens Com- Legion of the British Empire Service League,\" battants de l'Empire Britannique,\" une corpora- a corporation having its head office in the tion ayant son siège social en la cité d'Ottawa, City of Ottawa, Province of Ontario, will apply province d'Ontario, s'adressera à la Législature de to the Legislature of the Province of Quebec la province de Québec, à sa prochaine session, pour at its next Session for the passing of an Act obtenir l'adoption d'une Loi permettant au Com- to entitle the Quebec Provincial Command of mandement provincial de Québec de la Légion et the Legion and any Branch thereof to sue and toute succursale d'icelui de pourvuivre et être be sued in their respective names, to declare poursuivi en leurs noms respectifs, déclarer que that said Provincial Command or any such ledit commandement provincial ou toute telle Branch shall have no right or interest in the succursale n'aura aucun droit ou intérêt dans les assets of the other or be liable for any of the biens de l'autre ou ne sera responsable d'aucune debts, liabilities or obligations of the other and des dettes, engagements ou obligations de providing similarly in respect of the Dominion l'autre et pourvoyant de la même manière Command and to authorize the vesting in said en ce qui concerne le Commandement du Do- Provincial Command of the property of any minion et autoriser l'appropriation audit com- suspended Branch, mandement provincial des biens de toute succursale suspendue.Montréal, P.Q., 1er février 1950.Montreal, P.Q., February 1st, 1950.La Légion Canadienne de la Ligue des An- Canadian Legion of the British ciexs Combattants de l'Empire Britannique, Empire Service League, Le Secrétaire général, T.D.ANDERSON, 26701-5-4 T.D.ANDERSON.26761-5-4-o General Secretary Cité de Montréal City of Montreal AVIS NOTICE Avis public est par les présentes donné que Public notice is hereby given that the City of la Cité de Montréal s'adressera à la législature Montreal will apply to the Provincial Legislature, provinciale lors de la prochaine session pour at its next session, for the adoption of certain obtenir certaines modifications à sa charte, le amendments to its Charter, the Act 62 Victoria, statut 62 Victoria, chapitre 58, et aux différents Chapter 58, and to the various Acts amending statuts qui la modifient sur les matières sui- it, on the following matters: Tax exemptions; vantes: exemption de taxes; ratification dc cer- ratification of deeds: agreements, by-laws, retains actes: conventions, règlements, résolutions, solutions, rolls, plans, etc.; creation of a Transrôles, plans, etc.-; établissement d'une commis- portât ion Commission; membership of this sion de transport: composition de cette com- commission, salary of its members, powers of mission, salaire de ses membres, pouvoirs de la the City to avail itself of paragraph 8 of Article Cité de se prévaloir du paragraphe 8 de l'article 92 of the contract between the City and the 92 du contrat entre la Cité et la compagnie des Montreal Tramways Company, dated January tramways de Montréal en date du 28 janvier 28th 1918, on certain conditions, powers, rights, 191S à certaines conditions, pouvoirs, droits, authority and privileges, exercised exclusively autorité et privilèges exercés exclusivement par by the Commission, powers, rights, authority la commission, pouvoirs, droits, autorité et and privileges required to construct; operate, privileges requis pour la construction, l'exploi- control and administer subways, tubes or any tation, le contrôle et l'administration de métro- other means of mass transportation and of politains, voies tubulaires, ou tout autre moyen speedways exclusively entrusted to the Com-de transport en commun et d'autostrades con- mission, establisment of a Board of Arbitration, fiés exclusivement à la commission, établisse- adjustment of accounts and all funds, the prop-ment d'un tribunal d'arbitrage, ajustement des erty of the City, Commission, powers to cons-comptes et tous fonds, propriété de la Cité, truct, control, maintain, operate and administer commission, pouvoirs de contruire, de contrôler, new tramways lines, establish tariffs and rates, entretenir, exploiter et administrer les nou- expropriate all property considered necessary, velles lignes de tramways, fixer les taux et tarifs, obtain from the city all plans, etc., establish exproprier toute propriété jugée nécessaire, ob- its rules of procedure, Commission to report tenir de la Cité tous plans, etc.; établir ses règles annually to the City and books of Commission de régie interne, commission devra faire rapport subject to inspection by city auditors, Commis-annuel à la Cité et livres de la commission sujets sion may appoint employees, issue bonds with à l'inspection des vérificateurs de la Cité, com- or without guarantee by the City, City may mission peut nommer employés, émettre des issue bonds or guarantee those issued by the obligations avec ou sans garantie de la Cité, la Commission, Commission may invest all funds Cité peut émettre des obligations ou garantir in federal or provincial government or City of les obligations émises par la commission, com- Montreal securities, claims and actions against mission peut investir tous fonds dans des valeurs commission and commission may sue and be des gouvernements fédéral, provincial ou cité sued, notices of claims.de Montréal, réclamations ou poursuites contre la commission et commission peut poursuivre et être poursuivie, avis de réclamations.\u2022 Le Greffier de la Cité, J.ALPHONSE MONGEAU, w J.-ALPHONSE MONGEAU.City Clerk, bureau du Greffier de la Cité, City Clerk's Office, Hôtel de ville, City Hall, Montréal, le 1er février 1950.26765-5-4-0 Montreal, February 1st 1950.26765-5-4-0 688 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 février 1950, Tome 82, N° 8 Avis public est par les présentes donné que le Bureau Protestant des Commissaires d'Écoles de la ville de Magog s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à sa prochaine session pour amender la 2è partie du statut 53 Victoria, chap.79, pour autoriser ledit Bureau à changer les limites de la municipalité scolaire protestante de la ville de Magog, d'imposer et de faire la perception de taxes, et pour d'autres fins.Sherbrooke, ce 31è jour de janvier, 1950.Le Procureur du requérant, 26764-5-4-0 W.H.BRADLEY.Avis public est par les présentes donné que ^corporation \"Le Recteur et les Membres de l'Université Laval à Québec, dans la Province de Canada\" connue sous le nom de \"Université Laval\", s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa prochaine session, pour l'adoption d'une loi aux fins suivantes: lui confirmer son droit de posséder des biens immeubles en cette province et son pouvoir d'emprunter et d'hypothéquer, nantir ou mettre en gage ses biens mobiliers et immobiliers présents ou futurs, lui accorder le droit d'expropriation en certains cas de biens contigus à ceux de la corporation et le droit de décréter l'ouverture ou la fermeture de rues et chemins situés sur son établissement, et de passer avec les villes de Sillery et de Ste-Foy et avec la cité de Québec les conventions relatives à toutes matières municipales, ordonner que la corporation et ses biens soient exempts de taxes sous certaines conditions et pour autres fins.Québec, le 31 janvier 1950.Le Procureur de l'Université Laval, 26768-5-4-0 GUY HUDON.Public notice is heçeby given that The Protestant Board of School Commissioners of the Town of Magog will apply to the Legislature of the Province of Quebec at the next session thereof to amend Part II of the Act 53 Victoria, chapter 79, to authorize the said Board to alter the boundaries of the Protestant school municipality of the Town of Magog, to levy and collect taxes therein, and for other purposes.Sherbrooke, this 31st January 1950.W.H.BRADLEY, 26764-5-4-0 Attorney for the petitioners.Public notice is hereby-given that the corporation \"Le Recteur et les Membres de l'Université Laval à Québec, dans la Province de Canada known as \"Université Laval\" will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, for the passing of an Act for the following purposes: to confirm its rights to hold immoveable property in this Province, and its power to hypothecate mortgage and pledge any property, moveable or immoveable, present or future, to grant to the said corporation the right of expropriation of property contiguous to that held by the corporation, in certain cases; and its right to order that roads situated on its establishment be closed or opened and to enter with the town of Sillery and of St.Foy and the City of Quebec into agreements relating to all municipal matters; enact that the corporation and its property be exempted of taxes within certain conditions and for other purposes.Quebec, this 31st.day of January 1950.GUY HUDON, 26768-5-4-0 Attorney for L'Université Laval.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné qu'à la présente Session de la Législature de Québec demande sera faite par la Corporation des Techniciens Diplômés de la.Province de Québec, Corporation of Certified Technicians of the Province of Quebec, pour amender la loi concernant les techniciens diplômés, 8 Geo.VI, Chap.17, dans le but de définir les buts, les pouvoirs, les privilèges, droits et prérogatives de cette corporation ainsi que ceux de ses membres, conte nant d'autres dispositions relatives à cette corporation et plus spécialement en ce qui a trait à l'exercice de la profession de techniciens diplômés.Le Procureur de la pétionnaire, 26773-5-4-q LOUIS DUSSAULT, avocat.AVIS Avis est, par les présentes, donné que Miles Lawrence Williams et A.Lyle Williams, tous deux de la cité de Montréal, exécuteurs testamentaires de Miles Williams, en son vivant de ladite cité de Montréal s'adresseront à la Législature de la province de Québec, à sa prochaine session, pour obtenir l'adoption d'une Loi donnant auxdits exécuteurs pleins pouvoirs de vendre la propriété sujette aux substitutions créées par ledit testament de Miles Williams exécuté devant G.R.Lighthall, N.P.en date du 3 août 1886.Montréal, 1er février 1950.Les Procureurs des requérants, Scott, Hugessen, Macklaier, 26774-5-4 Chisholm & Hyde.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that at the present session of the Legislature of Quebec, application will be made by the Corporation of Certified Technicians of the Province of Quebec, Corporation des Techniens Diplômés de la Province de Québec, to amend the act respecting certified technicians, 8 VI Geo.Chap.17, in order to define the purposes, the powers, the privileges, rights and prerogatives of this corporation and its members, otherwise providing in respect of this corporation and *more especially in connection with the practice of the profession of certified technicians.LOUIS DUSSAULT, Advocate, 26773-5-4-0 Attorney for applicant.NOTICE Notice is hereby given that Miles Lawrence Williams and A.Lyle Williams, both of the City of Montreal, Executors under the Last Will and Testament of Miles Williams, in his lifetime of the said City of Montreal, will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its next Session for the passing of an Act giving to the said Executors full power of sale of the property subject to the substitutions created by the said Last Will and Testament of Miles Williams executed before G.R.Light-hall, N.P., on the 3rd August 1886.Montreal, February 1, 1950.Scott, Hugessen, Macklaier, Chisholm & Hyde, 26774-5-4-0 Solicitors for the Applicants. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 2fith, 1950, Vol.82, No.8 689 AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que la Cité de Longueuil s'adressera à la Législature*de la Province de Québec, à sa prochaine session, pour demander un amendement à sa charte, aux fins de changer la destination de certains lots qui lui ont été cédés, et d'obtenir le droit d'emprunter un montant 'plus élevé que celui prévu par l'article 2 de la loi 12 George VI, chapitre 60, et pour toutes autres fins s'y rattachant.Montréal, le 26 janvier 1950.Les Procureurs de la Cité de Longueuil, 26732-5-4-0 LAMARRE & LAMARRE.Canada, Province de Québec AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la Ville d'Amos s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à sa prochaine session, pour obtenir les pouvoirs suivants: 1° Évaluer les propriétés de la Filature de l'Abitibi Inc.à cinq mille dollars ($5,000.00), aux fins de taxation, et cela pour une période de dix (10) ans; 2° Acquérir l'actif, tant mobilier qu'immobilier, de la City Gas & Electric Corporation; 3° Évaluer à cinquante pour cent (50%) de leur valeur réelle, pour jusqu'à la fin de l'année 1955, les propriétés construites par des vétérans de la guerre de 1939.Amos, ce 23 janvier 1950.Le* Procureur de la Ville d'Amos, 26730-5-4-o L.A.LADOUCEUR.Avis pour Bill Privé Avis est par les présentes donné que la Ville de Loi lise vil le et les Commissaires d'Écoles pour la municipalité de la Ville de Louiseville, dans le comté de Maskinongé, présenteront à la prochaine Législature de Québec une pétition introductive-d'un bill privé, à l'effet de demander à la Législature de Québec de passer un bill leur donnant le pouvoir d'imposer et de prélever, en sus de toutes autres taxes, une taxe spéciale dite: \"Taxe de Vente\" n'excédant pas trois pour cent du prix de vente ou d'achat en détail.Louiseville, ce 31 janvier 1950.Le Procureur de la Ville de Louiseville et des Commissaires d'Écoles pour la Municipalité de la Ville de Louiseville dans le comté de Maskinongé, 26763-5-4-0 Me RÉMI PAUL, avocat.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the City of Longueuil will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, for an amendment to its charter, to change the destination of certains lots which were assigned to it, and to obtain the right to borrow an amount higher than that provided for in section 2 of the Act 12, George VI, chapter 60, and for~any other purposes incidental thereto.Montreal, January 26, 1950.LAMARRE & LAMARRE, 26732-5-4 Attorneys for City of Longueuil.Canada, Province of Quebec PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the town of Amos will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, for the following powers: 1.To assess the properties of the \"Filature de l'Abitibi Inc.\" at five thousand dollars, ($5,000) for taxation purposes, and such for a pariod of ten (10) years; 2.To acquire the assets, both movable and immovable, of the City Gas and Electric Corporation; 3.To assess at fifty per cent (50%) of their value, up to the end of the year 1955, the properties built by the Veterans of the war of 1939.Amos, January 23, 1950.L.A.LADOUCEUR, 26730-5-4 Attorney for the Town of Amos.Notice of Private Bill Notice is hereby given that the Town of Louiseville and the School Commissioners for the Municipality of Louiseville in the County of Maskinongé will present to the Legislature of Quebec, at its next session, a petition introducing a Private Bill, for the purpose of applying to the Legislature of Quebec for the passing of an Act giving it the power to levy and collect over and above all other taxes, a special tax called: \"Sales Tax\" not exceeding three percent of the retail sale or purchase price.Louiseville, this 31st day of January 1950.- Me RÉMI PAUL, Advocate, Attorney for the City of Louiseville and the School Commissioners of Louiseville, in the 26763-5-4-0 County of Maskinongé.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné, que la Corporation de la Paroisse du Lac St-Charles, s'adressera à la Législature de Québec, à sa prochaine session pour obtenir la modification de la loi A.Georges VI, chapitre 74, article 3, telle que modifiée par la loi 5 Georges VI, chapitre 72, article 15, pour, entr'autres, les fins suivantes: obtenir que soit incluse la Corporation de la Paroisse du Lac St-Charles dans le territoire assujetti à la taxe de vente de la cité de Québec.Québec, le 14 février 1950.Le Procureur de la pétitionnaire, 26842-7-4-0 VICTOR TRÉPANIER, C.R.PUBLIC NOTICE Public Notice is hereby given that the Corporation of the parish of Lac St-Charles shalL apply to the Quebec Legislature, at its next session, to obtain'the amendment of the act 4 George VI, chapter 74, section 3, as amended by the act 5 George VI, chapter 72, section 15, for, amongst other, the following purposes: obtain that the Corporation of the parish of Lac St-Charles be included in the territory subject to the sales tax in the city of Quebec.Quebec, February 14th 1950.* VICTOR TRÉPANIER, K.C., 26842-7-4-0 Attorney for the petitioner. 690 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 26 février I960, Tome 82, N° 8 AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné, que la Corporation de la Paroisse de Notre-Dame des Laurent ides, s'adressera à la Législature de Québec, à sa prochaine session, pour obtenir la modification de la loi 4, Georges VI, chapitre 74, article 3, telle que modifiée par le loi 5 Georges VI, chapitre 72, article 15, pour, entr'autres, les fins suivantes: obtenir que soit incluse la Corporation de la paroisse de Notre-Dame des Laurentides dans le territoire assujetti à la taxe de vente de la cité de Québec.Québec, le 14 février 1950.Le Procureur de la pétitionnaire, 26843-7-4-0 VICTOR TRÉPANIER, C.R.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné, que la Corporation de la Paroisse de Saint-Emile s'adressera à la Législature de Québec, à sa prochaine session, pour obtenir la modification de la loi 4, Georges VI, chapitre 74, article 3, telle que modifiée par la loi 5 Georges VI, chapitre 72, ar.ticlc 15, pour, entr'autres, les fins suivantes: obtenir que soit incluse la Corporation de la paroisse de Saint-Émile dans le territoire assujetti à la taxe de vente de la cité de Québec.Québec, le 14 février 1950.Le Procureur de la pétitionnaire, 26844-7-4-o VICTOR TRÉPANIER, C.R.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné, que la Corporation municipale de Stoneham s'adressera à la Législature de Québec, à sa prochaine sesssion, pour obtenir la modification de la loi 4, Georges VI, chapitre 74, article 3, telle que modifiée par la loi 5 Georges VI, chapitre 72, article 15, pour, entr'autres les fins suivantes: obtenir que soit incluse la Corporation municipale de Stoneham dans le territoire assujetti à la taxe de vente de la cité de Québec.Québec, le 14 février 1950.Le Procureur de la pétitionnaire, 26845-7-4-0 VICTOR TRÉPANIER, C.R.AVIS PUBLIC Avis est donné que Charles Côté, mécanicien, de Montréal, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à la prochaine session, pour obtenir une loi à l'effet de confirmer un jugement de la Cour Supérieure déclarant qu'il n'y a pas de substitution dans le testament de Dame Marie Joseph Lorange Côté.Montréal, le 9 janvier 1950.Le Procureur du requérant, 26850-7-4-o ALFRED TOURIGNY.PUBLIC NOTICE Public Notice is hereby given that the Corporation of the parish of Notre-Dame des Laurentides shall apply to the Quebec Legislature, at its next session, to obtain the amendment of the act 4 George VI, chapter 74, section 3, as amended by the act 5 George VI, chapter 72, section 15, for, amongst other, the following purposes: obtain that the Corporation of the parish of Notre-Dame des Laurentides be included in the territory subject to the sales tax in the city of Quebec.Quebec, February 14th, 1950.VICTOR TRÉPANIER, K.C., 26843-7-4-o Attorney for the petitioner.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the Corporation of «thc parish of St-Émile shall apply to the Quebec Legislature, at its next session, to obtain the amendment of the act 4 George VI, chapter 74, section 3, as amended by the act 5 George VI, chapter 72, section 15, for, amongst other, the following purposes: obtain that the Corporation of the parish of St-Emile be included in the territory subject to the sales tax in the city of Quebec.Quebec, February 14th, 1950.VICTOR TRÉPANIER, KG, 26844-7-4-o \u2022 Attorney for the petitioner.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the Municipal Corporation of Stoneham shall apply to the Quebec Legislature, at its next session, to obtain the amendment of the act 4 George VI, chapter 74, section 3.as amended by the Act 5 George VI, chapter 72, section 15, for, amongst other, the following purposes: obtain that the Municipal Corporation of Stoneham be included in the territory subject to the sales tax in the city of Quebec.Quebec, February 14th, 1950.VICTOR TRÉPANIER, K.C., 26845-7-4-0 Attorney for the petitioner.NOTICE Notice is hereby given that Charles Côté mechanic of Montreal, will ask the Legislature of the Province of Quebec at the next session to confirm a judgment of the Superior Court to the effect that there is no substitution in the will of Dame Marie Joseph Lorange Côté.Montreal, January 9, 1950.ALFRED TOURIGNY, 26850-7-4-o Attorney for petitioner.Avis public est par les présentes donné que la ville Montréal-Nord s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à sa session actuelle, pour faire amender sa charte en ce qui concerne le pouvoir d'emprunter temporairement par billets au cours de l'exécution 'de travaux municipaux et en ce qui concerne la répartition des taxes spéciales' sur les immeubles appartenant à la Ville, Montréal-Nord, 10 février 1950.\u201e Le Secrétaire-trésorier, 26851-7-4-0 A.-E.CHEVRIER.Public notice is hereby given that the Town of Montreal-North will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, to amend its charter regarding the power of borrowing temporarily by means of notes in the performance of municipal works and regarding the allotment of special taxes on immovables belonging to the town.Montreal-North, February 10, 1950.A.-E.CHEVRIER, 26851-7-4 Secretary-Treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 25th, MO, Vol.82, No.8 691 Avis public est par les présentes donné que la ville Saint-Michel s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à sa session actuelle, pour faire amender sa charte en ce qui concerne le pouvoir d'emprunter temporairement par billets au cours de l'exécution de travaux municipaux et en ce qui concerne la répartition des taxes spéciales sur les immeubles appartenant à la Ville.Ville Saint-Michel, 10 février 1950.Le Secrétaire-trésorier, 26852-7-4-0 A.-E.CHEVRIER.AVIS Avis est par les présentes donné que \"La Corporation de Prêt et Revenu\", de Québec, s'adressera à la prochaine session de la Législature de Québec, pour obtenir des pouvoirs additionnels concernant sa désignation, l'émission et la vente de ses certificats, le placement de ses fonds, l'acquisition et la possession d'immeubles, la procédure en cas de recouvrement de ses créances par vente forcée, et aussi certaines précisions au sujet des droits, qualifications et responsabilités de ses membres.Québec, le 11 février 1950.La Corporation de Prêt et Revenu, Parafe Trésorier, JEAN-PAUL TARDIF, 26864-7-4-0 Pétitionnaire.AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que la Dominion Foils (Canada) Limited s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à sa prochaine session pour obtenir la passation d'une loi modifiant le chapitre 66 de 10 George VI, 1940, pour étendre au 31 décembre 1955 la réduction des taxes consentie par la Corporation Municipale du Cap-de-la-Madcleine et au 31 juillet 1955, la réduction des taxes consentie par les Commissaires d'Écoles de la même Municipalité.Montréal, 15 février 1950.Le Procureur de la Requérante, 26865-7-4-0 MARCEL PICHÊ, C.R.Public notice is hereby given that the Town of Saint-Michel will apply to the Legislature of the Province of Québec, at its present session, to amend its charter regarding the power of borrowing temporarily by means of notes in the performance of municipal works and regarding the allotment of special taxes on immovables belonging to the town.Town of Saint-Michel, February 10, 1950.A.E.CHEVRIER, 20852-7-4 Secretary-Treasurer.s NOTICE Notice is hereby given that the \"La Corporation de Prêt et Revenu\", of Quebec, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, to obtain additionnai powers concerning the issuance and selling of its certificates, the investment of its funds, the acquisition and possession of immoveable properties, the procedure to be followed in case of enforced sales for the recovery of its assets and also some precision concerning the rights, qualification and responsibilities of its members.Quebec, this 11th of February, 1950.La Corporation de Prêt et Revenu, per: JEAN-PAUL TARDIF, Treasurer, 26864-7-4-0 Petitioner.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the \"Dominion Foils (Canada) Limited\" will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session for the passing of an Act amending chapter 66 of 10 George VI 1946, to extend to December 31st, 1955, the reduction of taxes granted by the municipal corporation of Cap-de-la-Madcleine, and to July 31st 1955, the reduction of taxes granted by the School Commissioners of the same Municipality.Montreal, February 15, 1950.MARCEL PICHÊ, K.C., 26865-7-4 Attorney for the Petitioner.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné, que la Corporation municipale de Saint-Gabriel-ouest de Valcarticr s'adressera à la Législature de Québec, à sa prochaine session, pour obtenir la modification de la loi 4, George VI, chapitre 74, article 3, telle que modifiée par la loi 5 George VI, chapitre 72, article 15, pour, entr'autres, les fins suivantes: obtenir que soit incluse la Corporation municipale de Saint-Gabriel-Ouest de Valcarticr dans le territoire assujetti à la taxe de vente de la cité de Québec.Québec, le 14 février 1950.Le Procureur de la pétitionnaire, 26867-7-4-0 VICTOR TRÉPANIER, C.R.AVIS LÉGAL Avis est par les présentes donné que la Municipalité Scolaire de la Cité de Salaberry de Valley-field, s'adressera à la Législature de Québec, lors de sa prochaine session, pour obtenir l'adoption d une loi l'autorisant à imposer et à percevoir une taxe de vente de un pour cent (1%) dans le même territoire, au même temps, de la même manière, PUBLIC NOTICE Public Notice is hereby given that the Municipal Corporation of Saint-Gabriel-West of Valcartier shall apply to the Quebec Legislature, at its next session, to obtain the amendment of the act 4 George VI, chapter 74, section 3, as amended by the act 5 George VI, chapter 72, section 15, for, amongst other, the following purposes : obtain that the Municipal Corporation of Saint-Gabriel-West of Valcartier be included in the territory subject to the sales tax in the city of Quebec.Quebec, February 14th, 1950.VICTOR TRÉPANIER, K.C., 26867-7-4-0 Attorney for the petitioner.LEGAL NOTICE Public notice is hereby given that the \"Municipalité Scolaire de la Cité de Salaberry de Valley-field\" will apply to the Legislature of Quebec, at its next session, for the passing of an Act, to authorise her to levy and collect a sale tax of one per cent (1%), in the same territory, at the same time, in the same manner, under the same condi- 692 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 25février 1950, Tome 82, N° 8 aux mômes conditions et avec les mêmes sanctions que la taxe perçue en vertu de l'article 118c, de la loi 22, George V, chapitre 111, tel que décrété par l'article 6, de la loi 4, George VI, chapitre 87, et leurs amendements.Salaberry de Valleyfield, le 14 février 1950.Les Procureurs de la Pétitionnaire, 26868-7-4-0 MELOCHE & PERRON.tions and with the same sanctions as the tax collected under section 118c, of the Act 22, George V, chapter 111, as enacted by section 6, of the Act 4, George VI, chapter 87, and their amendments.Salaberry-of-Valleyfield, February 14th, 1950.MELOCHE & PERRON, 26868-7-4-0 Attorneys for Petitioner.AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE Avis est par les présentes donné que le Bureau Notice is hereby given that the Board of des Commissaires des écoles catholiques de la Catholic School Commissioners of the town of ville de Magog, et le Bureau des Commissaires Magog, and the Board of Protestant School des écoles protestantes de la ville de Magog, Commissioners of the town of Magog, will s'adresseront à la législature de la province de apply to the Legislature of the Province of Québec, à sa prochaine session, dans le but de Quebec, at its next session for an amendment to demander un amendement à la deuxième partie the second part of the charter of the town of de la charte de la ville de Magog pour autoriser Magog, to authorize the said Boards of Catholic lesdits bureaux des commissaires des écoles ca- and Protestant School Commissioners of the tholiques et protestantes de la ville de Magog à town of Magog, to levy a sales tax of 1% within imposer une taxe de vente de 1% dans les limites the limits of the town of Magog, subject to the de la ville de Magog, sujette à la loi de la taxe Sales Tax Act, and to amend section 55 of 2 sur les ventes, et pour amender l'article 55 de 2 Geo.VI, 1938, chapter 114, for the purpose of Geo.VI, 1938, chap.114, aux fins d!autoriser authorizing the said Boards of Commissioners lesdits bureaux des commissaires de fixer toute to fix any amendment to the tax to be collected modification à la taxe qui doit être collectée sur on the immovable property of the town of Magog les propriétés immobilières de la ville de Magog, and for the purpose of making any other amend- et dans le but de faire tous autres amendements ments which may become necessary at the time qui pourraient devenir nécessaires lors de la pré- of the presentation of the bill, sentation du bill.Magog, January 20, 1950.Magog, ce 20 janvier, 1950.ALFRED TOURIGNY, L'Avocat du Bureau des Commissaires des écoles Attorney for the Board of Catholic School catholiques de la ville de Magog -et- Commissioners of the town of Magog-and- Avocat du Bureau des Commissaires des écoles Attorney for the Board of Protestant School protestantes de la ville de Magog, Commissioners of the town of Magog.26866-7-4-0 ALFRED TOURIGNY.26866-7-4 AVIS PUBLIC .PUBLIC NOTICE Avis public est par les présentes donné, que la Public notice is hereby given that the Corpora-Corporation de la Paroisse de St-Gabriel de Val- tion of the parish of St-Gabriel de Valcartier, cartier, s'adressera à la Législature de Québec, will apply to the Legislature of Quebec, at its à sa prochaine session, pour obtenir la modifica- next session for amendment to the Act 4, George tion de la loi 4, Georges VI, chapitre 74, article 3, VI, chapter 74, section 3, as amended by the Act telle que modifiée par la loi 5, Georges VI, cha- 5 George VI, chapter 72, section 15, for, amongst pitre 72, article 15, pour, entr'autres, les fins sui- others, the following purposes: to obtain that vantes: obtenir que soit incluse la Corporation the corporation of the parish of St-Gabriel de de la Paroisse de St-Gabriel de Valcartier dans le Valcartier be included in the territory subjected territoire assujetti à la taxe de vente de la cité de to the sales tax of the city of Quebec.Québec.Québec, le 17 février 1950.Quebec, February 17, 1950.Le Procureur de la Pétitionnaire, VICTOR TREPANIER, 26873-7-4-0 VICTOR TREPANIER.26873-7-4 Attorney for the Petitioner.AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE Avis public est par les présentes donné que Notice is hereby given that Alice O'Leary De-Alice O'Leary Desaulniers, Marguerite O'Leary saulniers, Marguerite O'Leary Lévesque, Dosta-Lévesque, Dostaler et Walter O'Leary, tous de 1er and Walter O'Leary,.of the city of West-la cité de Westmount, district de Montréal, s'a- mount, district of Montreal, will apply to the dresseront à la Législature de Québec, à sa pré- Legislature of Quebec, at its present session, sente session, pour demander l'adoption d'une praying for the passing of an act to amend cer-loi modifiant certaines dispositions du testament tain provisions of the last will and testament of de Charles Séraphin Rodier, leur arrière grand'- Charles Séraphin Rodier, their's great grand fa-père, aux fins d'autoriser les exécuteurs testa- ther, for the purposes of authorizing the testamentaires à verser une somme d'argent aux appe- mentary executors to paya sum of money to the lés ci-dessus énumérés.\u201e above enumerated institutes.Québec, le 17 février 1950.Quebec, February 17th, 1950.Le Procureur des pétitionnaires, VICTOR TRÉPANIER, K.C., 26886-8-4-o .VICTOR TRÉPANIER, C.R.26886-8-4-o Attorney for the pétitionner. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 25th, 1950, Vol 82, No.8 693 Ans de bill privé Avis est par les présentes donné que la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal demandera à la Législature à la Province de Québec, à sa prochaine session, l'adoption d'une loi aux fins suivantes: modifier le terme d'office de ses membres et de son conseil pédagogique; permettre la constitution de divers comités et pourvoir à la rémunération de leurs membres et de ceux du conseil pédagogique; dispenser la Commission de certaines formalités prévues par la loi relativement à rengagement des instituteurs, à la publication de certains avis, à l'approbation de ses règlements, achats, ventes, contrats, etc.; modifier les lois actuelles concernant le versement des sommes payables à la Commission par différentes municipalités pour fins scolaires; confirmer que la Commission n'est assujettie à aucune taxe ou imposition quelconque décrétée par une municipalité; modifier le mode de distribution et de partage de l'impôt prélevé aux termes de la loi 13 Geo.VI chapitre 75; pourvoir à indemniser les instituteurs au cas d'abandon prématuré de l'enseignement; payer une pension à Edouard Charles Piédalue; et pour autres fins.Montréal, 22 février 1950.L'Avocat de la requérante, 26914-8-4-0 JEAN TRUDEL, C.R.Notice op Private Bill Notice is hereby given that the Montreal Catholic School Commission will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act for the following purposes: To modify the term of office of its members and of its pedagogic council; to allow the institution of various committees and provide for the remuneration of its members and of those of the pedagogic council; to dispense the Commission from certain formalities provided by Law regarding the hiring of professors, the publication of certain notices, the approval of its by-laws, purchases, sales, contracts, etc.; to amend the present Laws regarding the remitting of sums payable to the- Commission by different municipalities for school purposes; to confirm that the Commission is not subject to any tax or levy whatsoever enacted by a municipality; to amend the method of distributing and apportioning the tax levied under the provisions of Act 13 Geo.VI, chapter 75; to provide for an indemnity for the teachers having to give up teaching prematurely; to provide for the payment of a pension to Edouard Charles Piédalue; and for other purposes.Montreal, February 22nd, 1950.JEAN TRUDEL, K.C., 26914-8-4 Attorney for the applicant.Actions en séparation de biens Canada, province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 282481.Germaine Dussault, des cité et district de Montréal, épouse commune en biens de Henri Lemay, électricien des cité et district de Montréal, demanderesse, vs Henri Lemay, électricien, des cité et distrct de Montréal, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 16 février 1950.Montréal, le 17 février 1950.Les Procureurs de la demanderesse, Perron, Michaud & Vincent.507 Place d'Armes, Montréal.26879-o Canada, province de Québec, district de St-François, Cour Supérieure, N° 7974.Dame Simonne Poulin, épouse commune en biens de Fernand Goulet, agent d'assurances, domiciliée en la cité de Sherbrooke, district de Saint-François, demanderesse, vs Fernand Goulet, agent d'assurances, domicilié en la cité de Sherbrooke, district de Saint-François, défendeur.Prenez avis qu'une action en séparation de biens a été instituée par la demanderesse.Sherbrooke, ce 17 février 1950.Les Procureurs de la demanderesse, 26898-0 (Signé) Veilleux & Péloquin.Avis divers La compagnie \"Léquatre Inc.\", constituée par lettres patentes du 22 décembre 1949, en vertu de la Loi des Compagnies de Québec, a établi son siège social à 593, rue St-Vallier, Québec.Québec, 19 janvier 1950.Le Président, *6897 Marguerite Paquet Beaumont.Actions for separation as to property Canada, Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.282481.Germaine Dussault, of the city and district of Montreal, wife common as to property of Henri Lemay, electrician, of the city and district of Montreal, 'plaintiff, vs Henri Lemay, electrician, of the city and district of Montreal, defendant.An action in separation as to property has been instituted in this case on February 16, 1950.Montreal, February 17, 1950.Perron, Michaud & Vincent, Attorneys for plaintiff.507 Place d'Armes, Montreal.26879 Canada, Province of Quebec, District of St.Francis, Superior Court, No.7974.Dame Simonne Poulin, wife common as to property of Fernand Goulet, insurance agent, domiciled in the city of Sherbrooke, district of Saint Francis, plaintiff vs Fernand Goulet, insurance agent, domiciled in the city of Sherbrooke, district of Saint Francis, defendant.Take notice that an action for separation as to property has been instituted by the plaintiff.Sherbrooke, February 17, 1950.(Signed) Veilleux & Péloquin, 26898 Attorneys for the plaintiff.Miscellaneous Notices The Company \"Léquatre Inc.\", incorporated by letters patent of 22nd of December 1949, under the Company Law of Quebec, has established its head pffice at 593, St.Vallier Street, Quebec City.Quebec, 19th of January, 1950.Marguerite Paquet Beaumont, 26897-0 President. 694 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26février 1960, Tome 82, N° 8 AVIS DE CHANGEMENT DE NOM (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a autorisé, le 30 janvier 1950, le change-gement de nom de r\"Assoeiation Catholique des des Institutrices Rurales du District N° 26\" en celui de \"L'Association des Institutrices Laïques de Portneuf-Québec, Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles que modifiées par 10, George VI, chapitre 20, article 3.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 31 janvier 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 26880-o JEAN BRUCHÊSI.NOTICE OF CHANGE OF NAME (Professional Syndicates' Act) Notice is givcn«that the Honourable the Provincial Secretary, on January 30, 1950, authorized the change of name of \"Association Catholique des Institutrices Rurales du District No.26\" to that of \"L'Association Catholique des Institutrices Laïques de Portneuf-Québec Inc.\", and such pursuant to the provisions of section 7, of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162, as amended by 10 George VI, chapter 20, section 3.Dated at the office of the Provincial Secretary January 31, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 26880 Under Secretary of the Province.AVIS DE CHANGEMENT DE NOM NOTICE OF CHANGE OF NAME (Loi des syndicats professionnels) (Professional Syndicates' Act) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Notice is given that thé Honourable the Prov-Province a autorisé, le 28 janvier 1950, le change- incial Secretary has authorized, on the 28th of Ja-ment de nom de 1'\"Association Catholique des nuary, 1950, the change of name of the \"Associa-Institutrices Rurales du District No 25, Inc.\" tion Catholique des Institutrices Rurales du Dis-en celui de \"L'Association Catholique des trict N° 25, Inc.\", into that of \"L'Association Institutrices Laïques du Comté de Portneuf, Catholique des Institutrices Laïques du Comté de Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de Portneuf, Inc.\", and such, pursuant to the pro-l'article 7 de la Loi des syndicats professionnels, visions of section 7 of the Professional Syndi-S.R.Q.1941, chapitre 162, telles que modifiées cates'Act, R.S.Q., 1941, chapter 162, as amended par 10, George VI, chapitre 20, article 3.by 10 George VI, chapter 20, section 3.Donné au bureau du Secrétaire de la Province Given at the office of the Provincial Secretary, le 30 Janvier 1950.this thirtieth day of January, 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, JEAN BRUCHÊSI, 26888-0 JEAN BRUCHÊSI.26888 Under Secretary of the Province.Negro Community Centre Règlement \"A\" \"Le nombre des membres du bureau de direction du \"Negro Community Centre\" sera et il est, par les présentes augmenté de six (6) à vingt (20).\" Copie conforme certifiée.Passé à l'unanimité à une assemblée générale des membres dûment convoquée et tenue le 27 décembre 1949.Montréal, 31 janvier 1950.Le Secrétaire, 26889 - DORIS WHEATLE.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une fédération de syndicats professionnels, sous le nom de \"Conseil Central des Syndicats Catholiques de l'Archidiocèse de Rimouski, Inc.\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la province le 14 février 1950.Le siège social de la fédération précitée est situé à Rimouski, comté de Rimouski.Le Sous-secrétaire de la Province, 26896-o JEAN BRUCHÊSI.Negro Community Centre By-Law \"A\" \"The number of the Board of Directors of \"Negro Community Centre\" shall be and it is hereby increased from six (6) to twenty (20).\" Certified a true copy, unanimously passed at a general meeting of the members, duly called and held on the 27th of December, 1949.Montreal, January «31st, 1950.DORIS WHEATLE, 26889-0 Secretary.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of a Federation of Professional Syndicates under the name of \"Conseil Central des Syndicats Catholiques de l'Archidiocèse de Rimouski, Inc.\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members has been authorized by the Provincial Secretary on February 14, 1950.The principal place of business of the said Federation is at Rimouski, county of Rimouski.JEAN BRUCHÊSI, 26896 - Under Secretary of the Province.AVIS DE CHANGEMENT DE NOM NOTICE OF CHANGE OF NAME (Loi des syndicats professionnels) (Professional Syndicates' Act) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Notice is given that the Honourable the Prov- Province a autorisé, le 17 février 1950, le change- incial Secretary, under date of February 17,19on, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 26th, I960, Vol.82, No.8 695 ment de nom de \"L'Union Nationale des Employés de Théâtre de la Province de Québec\" en celui de \"L'Union Nationale des Employés de Théâtre de la Province de Québec\" \u2014 National Union of Theatrical Employees of the Province of Quebec\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles que modifiées par 10 George VI, chapitre 20, article 3.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 20 février 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 26905-o JEAN BRUCHÊSI.authorized the change of name of \"L'Union Nationale des Employés de Théâtre de la Province de Québec\", to that of \"L'Union Nationale des Employés de Théâtre de la Province de Québec\" \u2014 \"National Union of Theatrical Employees of the Province of Quebec\", and such pursuant to the provisions of section 7 of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162, as amended by 10 George VI, chapter 20, section 3.Given at the office of the Provincial Secretary,\" February 20, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 26905 Under Secretary of the Province.résolution adoptée par la commission des resolution adopted by the quebec llquor Liqueurs de Québec Commission Vu une résolution adoptée par la Commission des Liqueurs de Québec, le 8 février 1950, et publiée dans la Gazette officielle de Québec, le 11 février 1950, établissant que le produit, à savoir: \"Vin St.Michel\", Laboratoire St.Michel, 4510, rue Cartier, Montréal.n'était pas un médicament au sens de l'art.51 de la Loi des liqueurs alcooliques mais bien une liqueur alcoolique; Vu que depuis le 15 février 1950, une nouvelle formule du dit \"Vin St.Michel\" a été soumise et approuvée par la Commission des Liqueurs de Québec; // est résolu: Que la Commission des Liqueurs de Québec établit par les présentes que le produit, à savoir: \"Vin St.Michel\", (nouvelle formule) Laboratoire St.Michel, 4510, rue Cartier, Montréal.n'est plus considéré comme une liqueur alcoolique mais bien comme un médicament au sens de l'art.51 de la Loi des liqueurs alcooliques.Montréal, le 21 février 1950.Le Conseil juridique, 2G895-0 J.N.VAILLANCOURT.Pursuant to a resolution adopted by the Quebec Liquor Commission, on the 8th of February, 1950, and published in the Quebec Official Gazette of the 11th of February 1950, establishing that the product, to wit: \"Vin St.Michel\" Laboratoire St.Michel, 4510 Cartier Street, Montreal.was not a medicament within the meaning of section 51 of the Alcoholic Liquor Act, but an alcoholic liquor; Seeing that since the 15th of February, 1950, a new formula for the said \"Vin St.Michel\" was submitted and approved by the Quebec Liquor Commission; It is resolved: That the Quebec Liquor Commission hereby establishes that the product, namely: \"Vin St.Michel\", (new formula) Laboratoire St.Michel, 4510 Cartier Street, Montreal.is no longer considered an alcoholic liquor but actually a medicament within the meaning of section 5fcof the Alcoholic Liquor Act.Montreal, February 21st., 1950.1 J.N.VAILLANCOURT, 26895-o Legal Adviser.A.Janin & Company Limited A.Janin & Compagnie Limitée Règlement N° 83 Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de la compagnie \"A.Janin & Company Limited\" \u2014 \"A.Janin & Compagnie Limitée\", ci-après nommée la compagnie, ce qui suit: 1.Que le nombre des membres du bureau de direction est, par les présentes, augmenté de quatre à sept.2.Que les règlements de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, modifiés pour se conformer au précédent.Décrété le 8 février 1950.Vraie copie.Le Secrétaire, 26908 C.J.MALONE.A.Janin & Company Limited A.Janin & Compagnie Limitée By-Law No.83 Be it enacted and it is hereby enacted as a By-law of \"A.Janin & Company Limited\" \u2014 \"A.Janin & Compagnie Limitée\" hereinafter called \"The Company\" as follows: 1.The number of members of the Board of Directors is hereby increased from four to seven.2.The By-Laws of the company be and they are hereby amended to accord with the foregoing.Enacted this 8th day of February, 1950.Jrue copy.26908-o C.J.MALONE, Secretary.W.H.Perron & Co.Limited Règlement N° A-l Diminution du nombre des directeurs W.H.Perron & Co.Limited By-Law No A-l To decrease the number of directors Le nombre des directeurs de la compagnie est, The number of Directors of the company is par les présentes, diminué de huit à trois et le hereby decreased from eight to three, and By- 696 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 25février 1950, Tome 82, N° 8 règlement N° 11, tel que préalablement amendé, est modifié en conséquence.Je, le soussigné, Secrétaire de la compagnie W.H.Perron & Co.Limited,\" certifie par les présentes, que le précédent est une copie conforme et exacte du règlement N° A-l de la compagnie \"W.H.Perron & Co.Limited.\" Montréal, 17 février 1950.m [Sceau] Le Secrétaire, 26909 J.G.MIRON.Les Industries Valox Limitée The Valox Industries Limited law No.11, as previously amended, is amended accordingly.I, the undersigned, secretary of \"W.H.Perron & Co.Limited,\" hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of By-law No A-l of \"W.H.Perron & Co.Limited\".Montréal, 17th of February, 1950.[Seal] J.G.MIRON, 26909-o Secretary.Les Industries Valox Limitée The Valox Industries Limited Extrait de minutes concernant la réduction du Excerpt from minutes concerning the decrease nombre des directeurs de cinq à quatre : in number of directors from five to four.\"Il est proposé, secondé et unanimement résolu que soit approuvée par les actionnaires la résolution passée par le Bureau d'Administration le 10 novembre 1949, se lisant comme suit: Que la section 7° du règlement N° 2 de la compagnie déjà amendée et qui se lit comme suit: \"7° Cinq administrateurs seront élus pour un an à l'assemblée annuelle, le quorum sera de trois\", soit amendée pour se lire comme suit: \"7° Quatre administrateurs seront élus pour un an à l'assemblée annuelle, le quorum sera de trois.\" Extrait dûment certifié, Québec, ce 10 janvier 1950.Le Secrétaire-trésorier, 26910-o ROSAIRE CARON.\"It was moved, seconded and unanimously resolved that the resolution, passed by the board of directors on November 10, 1949, be approved by the shareholders to read as follows: That section 7.of by-law No.2 of the company already amended and which reads as follows: \"7.Five directors shall be elected for one year at the annual meeting, the quorum being three\", be amended to read as follows: 7.Four directors shall be elected for one year at the annual meeting, the quorum being three.\" Excerpt duly certified, Quebec, January 10, 1950.ROSAIRE CARON, 26910 Secretary-Treasurer.Avis est donné que, sur recommandation de l'Assistant-procureur général, l'Honorable Secrétaire de la Province a approuvé, en date du 21 février 1950, les règlements Nos 1 et 2 de \"Thorn-hill Park Association\", conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 276), telles que modifiées par la Loi 10, George VI, chapitre 20, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 23 février 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 26911 JEAN BRUCHÊSI.Notice is hereby .given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved on February 21st, 1950, the By-laws Nos 1 and 2 of the \"Thornhill Park Association\", pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act (R.S.Q.1941, chapter 276), as amended by the Act 10, George VI, chapter 20, section 5.Given at the office of the Provincial Secretary the 23rd of February, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 2691 l-o Under Secretary of the Province.Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le 22 février 1950, les règlements généraux, comprenant les articles 1 à 9 inclusivement, de l'\"Association des Sports d'Hiver de Québec\" (Quebec Winter Sports Association), tels qu'adoptés à une assemblée générale spéciale tenue le 18 novembre 1949, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 276), telles que modifiées par 10, George VI, chapitre 20, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 23 février 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 26917-0 JEAN BRUCHES» Notice is given that upon recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary, under date of February 22, 1950, approved the general by-laws, including articles 1 to 9 inclusively, of the \"Association des Sports d'Hiver de Québec\" (Quebec Winter Sports Association), as adopted at a special general meeting held on November 18, 1949, and such pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act (R.S.Q.1941, chapter 276), as amended by 10 George VI, chapter 20, section 5.Given at the office of the Provincial Secretary, February 23, 1950.JEAN BRUCHESI, 26917 Under Secretary of the Province.Avis est donné que, sur recommandation de l'Assistant-procureur général, l'Honorable Secrétaire de la Province a approuvé, en date du 22 février 1950, le règlement \"B\" modifiant le règlement VII, article 1, et le règlement \"C\" modifiant le règlement VI, article 2 de \"Quebec Brewers Association\" \u2014 \"L'Association des Brasseries de la Province de Québec\", tels qu'adoptés aux assemblées générales spéciales tenues les 14 Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honorable the Provincial Secretary has approved on February 22nd, 1950, By-Law \"B\" amending By-Law VII, Article 1, and By-Law \"C\" amending By-Law VI, Article 2, of the \"Quebec Brewers Association\" \u2014 \"L'Association des Brasseries de la'Province de Québec\", as adopted at Special General Meetings held on September 14tn, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 26th, 1960, Vol.82, No.8 697 septembre 1949 et 23 janvier 1950, conformément 1949 and on January 23rd, 1950, pursuant to the aux dispositions de l'article 225a de la Loi des provisions of section 225a of the Quebec Com- compagnies de Québec (S.R.Q.1941, chapitre panics Act (R.S.Q.1941, chapter 276), as added 276), telles qu'ajoutées par la Loi 11 Geo.VI, thereto by the Act 11 Geo.VI, ch.65, section 12.chapitre 65, article 12.Donné au bureau du Secretaire de la Province, Given at the office of the Provincial Secretary le 23 février 1950.the 23rd of February, 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, JEAN BRUCHÊSI, * 26918 JEAN BRUCHÊSI.26918-0 Under Secretary of the Province.* Chartes \u2014 Abandon de Charters \u2014 Surrender of Canada, Province de Quebec, District de Bedford Canada, Province of Quebec, District of Bedford AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE Avis de demande d'abandon de Notice of Application of Surrender of sa charte charter Avis est par les présentes donné que \"P.A.Notice is hereby given that \"P.A.Pelletier & Pelletier & Fils Limitée\" corps politique et in- Fils Limitée\", a body politic and incorporated corporé en vertu de la Loi des Compagnies de la under the Quebec Companies Act, and having its province de Québec et ayant sa principale place principal place of business at No.114-A Main d'affaires au N° 114-A de la rue Principale, en la St., in the city of Granby, district of Bedford, will cité de Granby, district de Bedford, demandera apply to the Attorney General and the Minister au Procureur Général et au Ministre des Affaires of Municipal Affaire, Trade and Commerce of municipales de l'Industrie et du Commerce de la the Pmvince of Quebec for leave to surrender its Province de Québec, la permission d'abandonner charter incorporating said company, sa charte la constituant en corporation.Le tout en vertu de la Loi des Compagnies de The whole pursuant to the Quebec Companies Quebec.Act.Granby, le 10 février 1950.Granby, February 10, 1950.Le Président, (Signed) L.P.PELLETIER, 26881-u (Signé) L.P.PELLETIER.26881 President.Avu est donné que la compaguie\"Plymouth Notice is hereby given that \"Plymouth Real-Realties Limited\" demandera la permission d'a- ties Limited\", will apply for leave to surrender its handonner sa charte, conformément à l'article 26 charter, pursuant to section 26 of the Quebec de la Loi des compagnies de Québec.Companies Act.Montréal, 16 février 1950.Montreal, February 16th, 1950.Les Procureurs de la requérante, FELS & FELS, 2C882 FELS & FELS.26882-o Attorneys for Applicant.Avis est par les présentes donné que la compa- Notice is hereby given that \"R.M.Rainville & gnie dite \" R.M.Rainville & Company Limited\", Company Limited\", incorporated by letters pa- constituée en corporation par lettres patentes de tent of the Province of Quebec, dated December la Province de Québec, en date du 13 décembre 13th, 1940, will make application for leave to sur- 1940, demandera la permission d'abandonner sa render its charter, charte.Montréal, le 3 février 1950.Montreal, February 3rd, 1950.Le Procureur de la compagnie dite NORMAN N.GENSER, R.M.Rainville & Company Limited, Attorney for 26890-o NORMAN N.GENSER.26890 R.M.Rainville & Co.Ltd.Avis de demande d'abandon de charte Notice of Application for Surrender of Charter Federal Hosiery Mills Limited Federal Hosiery Mills Limited Avis est donné que la compagnie \"Federal Notice is hereby given that \"Federal Hosiery Hosiery Mills Limited\", constituée en corpora- Mills Limited\", a corporation constituted under tion en vertu de la Loi des compagnies de Québec, the Quebec Companies Act and having its head et ayant son siège social en la cité de Granby, office in the city of Granby, Quebec, will apply Québec, s'adressera au Procureur-général de la to the Attorney General of the Province of Quebec ^province de Québec pour obtenir la permission for leave to surrender its charter under the provi- d'abandonner sa charte conformément aux dis- sions of the Quebec Companies Act.positions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Toronto, le 30 janvier 1950.Dated at Toronto, Ontario, this 30th day of January, 1950.Le Secrétaire, W.N.N.SMITH, 26913 W.N.N.SMITH.26913-0 Secretary. 698 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 février 1960, Tome 82, N° 8 Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu auProcureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Business Educations Inc.\", incorporée par lettres patentes en date du quatorze novembre 1946.Avis est de plus donné qu'à compter du 1er avril 1949, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 23 février 1950.L'Assistant-procureur général, 26919 L.DÊSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 25, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Business Educations Inc.\", incorporated by letters patent dated the 14th day of November, 1946.Notice is also given that from and after the 1st day of April, 1949, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the 23rd day of February, 1950.L.DÊSILETS, 26919-o Deputy Attorney General.Département de l'Instruction publique N° 1489-49 Québec, le 23 février 1950.Demande est faite d'annexer à la municipalité scolaire catholique de Hudson, dans le comté de Vaudreuil, le territoire de la municipalité scolaire de Como-Est, dans le même comté, telle qu'érigée par arrêté ministériel en date du 6 avril 1923, c'est-à-dire le territoire du dit village tel qu'érigé par proclamation en date du 8 février 1918 publiée dans la Gazette officielle de Québec du 16 février de la même année.Le Surintendant de l'Instruction publique, .26904-8-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 1470-38.Québec, le 8 février 1950.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Cameron, dans le comté de Gatineau et de l'ériger en municipalité scolaire distincte, sous le nom de \"Sainte-Thérèse\", comté de Gatineau, le territoire suivant qui sera borné comme suit, savoir: Au nord, par la ligne qui sépare le canton Cameron du canton de Kensington; au sud, par le ruisseau appelé Port Creek, situé sur les lots trente-huit et trente-neuf du rang II du canton de Cameron; par une ligne passant au centre des lacs au Rat et Rond et le lot trente du rang VI du même canton; à l'est, par le lac trente-et-un milles ou Lac Commissaires et à l'ouest par la Rivière Gatineau.Le Surintendant de l'Instruction publique, 26840-7-2-o O.J.DESAULNIERS.Département des Terres et Forêts Department of Education No.1489-49.Quebec, February 23, 1950.Application is made to annex to the Catholic School Municipality of Hudson, in the county of Vaudreuil, the territory of the school municipality of Como-East, in the same county, as erected by order in council bearing date April 6,1923, namely, the territory of the said village as erected by Proclamation, under date of February 8, 1918, published in the Quebec Official Gazette, of February 16, of the same year.O.J.DESAULNIERS, 26904-8-2 Superintendent of Education.No.1470-38 Quebec, February 8, 1950.Application is made to detach from the school municipality of Cameron, in the county of Gatineau, and to erect into a separate school municipality, under the name of \"Sainte-Thérèse, county of Gatineau, the following territory, which shall be bounded as follows, to wit: On the north by the line separating the township of Cameron from the township of Kensington; on the south by the stream called Port Creek, situate on lots thirty-eight and thirty-nine, of range II of the township Cameron; by a line passing in the middle of Lakes \"au Rat' and \"Rond\" and lot thirty of range VI of the same township; on the east by \"lac trente-et-un milles\" or \"lac Commissaires\" and on the west by the Gatineau River.O.J.DESAULNIERS, 26840-7-2 Superintendent of Education.Department of Lands and Forests AVIS Cadastre officiel du canton Adstock.Division d'enregistrement de Frontenac.Avis est par la présente donné que dans le rang XI, le lot 23B est annulé'et les lots 23A et 23J sont corrigés en vertu des articles 2174A et 2174 du Code civil.Québec, le 2 février 1950.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 26906-o AVILA BÉDARD.NOTICE Officiai cadastre of the township of Adstock.Registration division of Frontenac.Notice is hereby given that in Range XI.lot 23B is cancelled and lot 23A and 23J are corrected in virtue of Articles 2174A and 2174 or the civil Code.Quebec, February the 2nd, 1950.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 26906-o * Deputy Minister. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 25th, 1950, Vol 82, No.8 699 AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Victoire canton d'Arthabaska (maintenant ville de Victoriaville) Division d'enregistrement d'Arthabaska.Avis est par la présente donné que le lot 97-252 (rue) est annulé en vertu de l'article 217A4 du Code civil.Québec, le 14 février 1950.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 26906-O AVILA BÉDARD.NOTICE Officiai Cadastre of the Parish of Ste.Victoire Township of Arthabaska (now town of Victoriaville) Registration Division of Arthabaska.Notice is hereby given that lot 97-252 (street) is cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, February the 14th, 1950.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 26906-o Deputy Minister.Greffes de Notaires Avis est par le présent donné, conformément aux dispositions du Code du Notariat, que le Conseil de la Chambre des Notaires, à sa réunion qui a été tenue à Montréal le 16 février 1950, a accordé à Me Paul H.Moncion, notaire demeurant et exerçant à Maniwaki, district judiciaire de Hull, la transmission des minutes, répertoire et index de Me Léon J.Raymond, Greffier de la Chambre des Communes, qui a cessé d'exercer.Montréal, 25 février 1950.Le Secrétaire-trésorier de la Chambre des Notaires, 26891-0 ARTHUR COMTOIS.Notarial Records Notice is hereby given pursuant to the provisions of the Notarial Code, that the Council of the Board of Notaries, at its meeting held in Montreal, on the 16th of February 1950, has granted to Me Paul H.Moncion, Notary residing and practising at Maniwaki, judicial district of Hull, the transfer of the minutes, repertory and index of Me Léon J.Raymond, Clerk of the House of Commons who has ceased practising.Montreal, February 25th, 1950.ARTHUR COMTOIS, Secretary-Treasurer of the Board 26891-0 - of Notaries.Nomination Il a plu à son Honneur le Lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil exécutif, et par commission, de faire la nomination suivante: Québec, 1er février 1950.M.Paul-Edouard Martin, huissier, 35, rue Iberville, Rivière-du-Loup: shérif du district de Kamouraska et officier spécial chargé de la confection et de revision de la liste des jurés pour ce district, ledit Paul-Edouard Martin étant en outre nommé commissaire \"per dedim.ua potesta-tem\", le tout à compter du 16 février 1950.2G916-0 Proclamation Canada, Province de EUG.FISET Québec.(L.S.] GEORGE VI, par la grâce de Dieu, Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Défenseur de de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut.PROCLAMATION VAssistant-procureur ( A TTENDU que l'ho-gcnéral, norable Ministre des L.Désilets.(terres et forêts de Notre Appointment His honour the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the Executive Council, and by Commission, to make the following appointment : Quebec, February 1, 1950.Mr.Paul Edouard Martin, bailiff, 35 Iberville Street, Rivière-du-Loup: to be Sheriff of the district of Kamouraska and special officer entrusted with the making and revising of the jury list for this district, the said Paul Edouard Martin, being, moreover, Commissioner, \"per dedimus potestatem\"', the whole, from and after February 16, 1950.26916 Proclamation Canada, Province of EUG.FISET Quebec.[L.SJ GEORGE VI, by the Grace of God, of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, King, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern.Greeting.PROCLAMATION L.Désilets, /t\\ 7HEREAS the Honoura-Deputy Attorney < vv ble the Minister of General (.Lands and Forests of Our 700 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 25 février I960, Tome 82, N° 8 province de Québec a fait préparer, sous sa direction, conformément aux dispositions du paragraphe 1A de l'article 3 de la Ix>i 21 George V, chap.104, deux plans et deux livres de renvoi revisés: 1.d'une partie du canton de Demeules, comprise dans les limites de la ville de Saint-Félicien; 2.\u2014 d'une partie du canton d'Ashuapmou-chouan, comprise dans les limites de la ville de St-Félicien; dans la division d'enregistrement de Lac St-Jean-Ouest; Attenou que ces plans et livres de renvoi revisés font maintenant partie des archives du département des terres et forêts, et qu'une copie exacte a été déposée au bureau de la division d'enregistrement de Lac St-Jean-Ouest; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif, exprimés dans l'arrêté en conseil no 133, en date du 1er février 1950, et conformément aux dispositions des articles 2174 et 2174A du Code civil et du paragraphe 1A de l'article 3 de la Loi 21 George V, chap.104.Nous donnons avis du dépôt de ces plans et livres de renvoi revisés mentionnés ci-dessus au bureau de la division d'enregistrement qu'il appartient, lequel est mentionné ci-dessus, et Nous fixons à la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, le jour auquel les dispositions de l'article 3, par.c.de la Loi modifiant les articles 2174A et 2175 du Code civil, (21 Geo.V, chap.104) deviendront en vigueur, relativement à cette partie des cantons de Demeules et d'Ashuap-mouchouan, comprise dans les limites de la ville de St-Félicien; et Nous invitons toute personne intéressée, à peine de perdre la priorité conférée par la loi, à renouveler, dans l'année qui suit la date fixée ci-dessus, toutes les hypothèques affectant particulièrement aucun des lots aux plans et livres de renvoi et non comprises les hypothèques affectant tout le terrain subdivisé.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé le Major-général l'honorable Sir EUGENE-MARIE-JOSEPH FISET, Kt, C.M.G., D.S.O., M.D., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce premier jour de février en l'année mil neuf cent cinquante de l'ère chrétienne et de Notre Règne la quatorzième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 26920-o JEAN BRUCHÊSI.Province of Quebec, has caused to be prepared under his direction, pursuant to the provisions of paragraph 1A of section 3 of the Act 21 George V, chap.104, two revised plans and books of reference; 1.of a part of the township of Demeules, comprised within the limits of the town of St-Félicien; 2.of a part of the township of Ashouapmou-chouan, comprised within the limits of the town of St-Félicien; in the Registration Division of Lake St.John West.Whereas said revised plans and books of reference now form part of the archives of the Department of Lands and Forests ^ and that an exact copy was filed in the registration Division of Lake St.John West; Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in Order in Council No.133, dated February 1st, 1950, and pursuant to the provisions of articles 2174 and 2174A of the Civil Code and of paragraph 1A of section 3 of the Act 21 George V, chap.104.We give notice of the filing of said revised plans and books of reference, hereinabove mentioned, at the office of the Registration Division to which they belong, same as hereinabove mentioned, and We fix the date of the present proclamation in the Quebec Official Gazette the day upon which the provisions of section 3, par.c.of the Act amending 2174A and 2175 of the Civil Code (21 Geo.V, chap.104) shall come into force respecting that part of the townships of Demeules and of Ashuapmouchouan, comprised within the limits of the town of St-Félicien; and We invite all interested parties, on pain of losing the priority conferred by the Act, to renew within one year following the date hereinabove fixed, all the hypothecs particularly affecting any of the plans and books of reference and not comprising the hypothecs affecting the whole of the subdivided land.Of all of Which Our loving subjects and all others, whom these presents may concern, are hereby required to take note and to govern themselves accordingly.In testimony Whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well Heloved Major General, the Honourable Sir EUGENE-MARIE-JOSEPH FISET, Kt, C.M.G., D.S.O., M.D., Lieutenant-Governor of Our said Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this twenty-first day of February, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and fifty and the fourteenth of Our Reign.By command, * JEAN BRUCHÊSI, 26920 Under Secretary of the Province.Sièges sociaux Head Offices Campbells' Florists Incorporated Campbells' Florists Incorporated Règlement N° 88 By-Law No.88 Le siège social de la compagnie, autrefois situé \"The head office of the company, previously à 1176 ouest, rue Ste-Catherine, en la cité de situated at 1176 St.Catherine St.West, in the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 25th, 1950, Vol.82, No.8 701 Montréal, sera maintenant transporté à 4706 avenue Westmount, en la cité de Westmount.Copie conforme certifiée.Le Président, ANNE M.CULROSS.Le Secrétaire, 26883 AMY GORDON MAW.Extrait des Minutes d'une assemblée des directeurs de \"Gagnon Transport Ltée,\" tenue le 14 janvier 1950.\"Sur proposition dûment secondée, il est résolu que le bureau-chef de la compagnie soit situé à 24, rue Hermine, Québec.Certifiée vraie copie.[Sceau] lie Secrétaire, 26884-0 JACQUES JUNEAU.Avis delà situation du bureau principal de \"Gaston Bourassa, Ltée.\" Avis est donné que la compagnie \"Gaston Bourassa, Ltée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 28 décembre 1949, et ayant son bureau principal dans la cité de Trois-Rivières, a établi son bureau au numéro 7296 de la rue Père Marquette, dans la dite cité.A compter de la date du présent avis, le dit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Trois-Rivières, ce 7ème jour de fé-vier, 1950.Le Secrétaire-trésorier dûment autorisé, 26892-0 J.EUG.FERRON.city of Montreal, will now be changed to 4706 Westmount Ave., in the city of Westmount.\" Certified true copy.ANNE M.CULROSS, President.AMY GORDON MAW, 26883-o Secretary.Excerpt from the minutes of a meeting of the directors of \"Gagnon Transport Ltée\", held on January 14, 1950.\"Upon its being moved and duly seconded, it is resolved that the head office of the company be situate at \"24 Hermine Street, Quebec.Certified true copy.[Seal] JACQUES JUNEAU, 26884 * Secretary.Notice of situation of head-office of \"Gaston Bourassa, Ltée\".Notice is given that the company \"Gaston Bourassa, Ltée\", incorporated by letters patent dated December 28, 1949, and having its head office in the city of Trois-Rivières, has established its office at number 7296 Père Marquette street, in the said city.From and after the date of the present notice the said office will be considered by the company as being its head office.Given at Trois-Rivières, this seventh day of February, 1950.+ J.EUGENE FERRON, 26892 Duly authorized Secretary Treasurer.Avis de la situation du bureau principal de la compagnie \"Les Produits d'Acier Atomik Steel Products, Inc.\"' Avis est donné par les présentes que la compagnie \"lies Produits d'Acier AtomÛc Steel Products, Inc.\", constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts Refondus de Québec, Chapitre 276, par lettres patentes datées du 31 décembre 1949, enregistrées le 11 janvier 1950, Libro 226, Folio 117 et ayant son bureau principal dans la cité de Montréal, a établi son bureau à la chambre 812, Edifice Thémis, 10, ouest, rue St-Jacques, dans les cité et district de Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie, comme étant son bureau principal.Montréal, le 8 février 1950.[Sceau] Le Président, 26893-0 ARSENE MÉNARD.Avis est donné que la compagnie \"Thornhill Park Association\", une corporation constituée en corporation par lettres patentes en date du 20 juillet 1949, et ayant son siège social en la cité de Québec, a établi son bureau à chambre 228, 65 rue Ste-Anne, Québec, P.Q.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la co mpagnie comme étant son siège social.Daté à Québec, P.Q., le 3 février 1950.Le Secrétaire, 2«912 C.DOUGLAS JOHNSTON.Notice of situation of the Head Office of the company \"Les Produits d'Acier Atomik Steel Products, Inc.\" Notice is hereby given that the company \"Les Produits d'Acier Atomik Steel Products, Inc.\", incorporated by letters patent under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, by letters patent dated December 31, 1949, registered on January 11, 1950, Libro 226, Folio 117, and having its head office in the city of Montreal, has established its office at Room 812, Themis Building, 10 St.James Street West, in the city and district of Montreal.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Montreal, February 8, 1950.[Seal] ARSENE MÉNARD, 26893 President.Notice is hereby given that \"Thornhill Park Association\", a corporation incorporated by letters patent on the 20th day of July, 1949, and having its head office in the city of Quebec, has established its office at Room 228, 65 St.Anne Street, Quebec, P.Q.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the corporation as being the head office of the corporation.Dated at Quebec, P.Q., this 3rd day of February, 1950.C.DOUGLAS JOHNSTON, 26912-0 Secretary. 702 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 février 1950, Tome 82, N° 8 Avis de la situation du bureau principal de la compagnie \"Roméo Inc.\".Avis est donné par les présentes que la compagnie \"Roméo Inc.\" constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, chapitre 276, par lettres patentes datées du 23 mai 1949, enregistrées le 2 juin 1949, Libro 224, Folio 34, et ayant son bureau principal dans la cité de Montréal, a établi son bureau au no.5450 boulevard Pie IX, dans les cité et district de Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie, comme étant son bureau principal.Montréal, le 7 février 1950.[Sceau] Le Président, 26894-0 LEO DAVIGNON.Soumissions Notice of situation of head office of the companA* \"Roméo Inc.\" Notice is hereby given that the company \"Romeo Inc.\", incorporated by letters patent under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, by letters patent dated May 23, 1949, registered on June 2, 1949, Libro 224, Folio 34, and having its head office in the city of Montreal, has established its office at No.5450, Pie IX Boulevard, in the city and district of Montreal.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Montreal, February 7, 1950.[Seal] LEO DAVIGNON, 26894 President.Tenders Province de Québec Province of Quebec Commission Scolaire du Village de Warwick School Commission of the Village of Warwick Comté d'Arthabaska County of Arthabaska Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Wilfrid Mailhot, 355 rue St-Louis, Warwick, Que., jusqu'à 8 heures p.m.lundi le 13 mars 1950, pour l'achat de $140,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la Municipalité de Warwick Village, datées du 1er avril 1950 et remboursables par séries du 1er avril 1951 au 1er avril 1970 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 3}4% par année payable semi-an-nuellement les 1er avril et le 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant : Tableau d'amortissement \u2014 $140,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er avril 1951.x$15,500.00 1er avril 1952.x 16,000.00 1er avril 1953.x 16,500.00 1er avril 1954.*.x 17,000.00 1er avril 1955.3,500.00 1er avril 1956.3,500.00 1er avril 1957.4,000.00 1er avril 1958.4,000.00 1er avril 1959.4,000.00 1er avril 1960.4,000.00 1er avril 1961.4,500.00 1er avril 1962.4,500.00 1er avril 1963.4,500.00 1er avril 1964.5,000.00 1er avril 1965.5,000.00 1er avril 1966.5,500.00 1er avril 1967.-5,500.00 1er avril 1968.5,500.00 1er avril 1969.6,000.00 1er avru^tfO.6,000.00 Les x indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $57,-000.00 accordé par le Secrétaire de la Province et payable en quatre versements de $14,250.00 chacun, de 1951 à 1954 inclusivement, seront reçus et appliqués au service do cet emprunt.Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Wilfrid Mailhot, 355 St-Louis St., Warwick, Que., up to 8 o'clock p.m.Monday, March 13, 1950, for the purchase of $140,000 of bonds of the School Commissioners, for the Municipality of Warwick Village dated April 1st, 1950 and redeemable serially from April 1st, 1951 to April 1st, 1970 inclusively, with interest at a rate not exceeding 3j^% per annum, payable semi-armually the 1st of April and 1st of October of each year.The rate of interest offered may be the same for the total issue or may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of Redemption \u2014 $140,000.00 \u2014 20 years Year Capital April 1st 1951.x$15,500.00 April 1st 1952.x 16,000.00 April 1st 1953.x 16,500.00 April 1st 1954.x 17,000.00 April 1st 1955.3,500.00 April 1st 1956.3,500.00 April 1st 1957.\\.4,000.00 April 1st 1958.4,000.00 April 1st 1959.4,000.00 April 1st 1960.4,000.00 April 1st 1961.4,500.00 April 1st 1962.4,500.00 April 1st 1963.4,500.00 April 1st 1964.5,000.00 April 1st 1965.5,000.00 April 1st 1966.5,500.00 April 1st 1967.,.5,500.00 April 1st 1968.5,500.00 April 1st 1969.6,000.00 April 1st 1970.6,000.00 The \"x\" indicates the years during which the annual instalments of a total grant of $57,001) granted by the Provincial Secretary and payable in four instalments of $14,250.00 each, from lwj to 1954 inclusively, shall be received and applied to this loan. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 25th, 1950, Vol 82, No.8 703 Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Warwick.Les dites obligations pourront, en vertu des dispositions du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, à toute échéance d'intérêt, au pair; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant total de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires qui sera tenue le 13 mars 1950, à 8.30 p.m.à la Salle des Chevaliers de Colomb de Warwick.Les commissaires se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Daté à Warwick, ce 13ème jour de février 1950.Le Secrétaire-trésorier, WILFRID MAILHOT.355, rue St-Louis, Warwick, Que.2G885-0 Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or Warwick.The said bonds may, under the provisions of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec, 1941, be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par; at any interest payment date; however, if such redemption be partial, the bonds will be called in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the total amount of the loan and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and considered at a meeting of Commissioners to be held on March 13, 1950, at 8 o'clock p.m., at the Knights of Columbus Hall, xat Warwick.The Commissioners do not bind themselves to accept the highest nor any of the tenders.Dated at Warwick, this 13th day of February, 1950.WILFRID MAILHOT, Secretary-Treasurer.355 St-Louis St., Warwick, Que.26885 Ventes d'effets non réclamés Sales of Unclaimed Baggage Avis est par les présentes donné que tous les Notice is hereby*given that all baggage re-effets de bagage reçus avant le douzième jour ceived prior to the 12th day of April, 1949, and d'avril 1949 et non réclamés aux bureaux de la still remaining unclaimed in the offices of the \"Canadian Pacific Railway Company\", seront Canadian Pacific Railway Company, will be vendus aux enchères par MM.Fraser Bros., .sold by public auction to the highest bidder by 901 rue Saint-Jacques ouest, Montréal, à 10 Messrs.Fraser Bros., auctioneers, at 901 St.Ja-heures de l'avant-midi, mercredi le douzième mes'St.West, Montreal, at ten o'clock in the jour d'avril 1950, en conformité de la Loi des forenoon, on Wednesday, April 12th, 1950, un-Chemins de Fer du Canada, à moins que les dits der the authority of The Railway Act of Canada, effets ne soient réclamés et tous les frais payés unless same shall be called for before date and all avant cette date.charges paid thereon.Montréal, le 17 février 1950.Montreal, February 17th, 1950.Canadian Pacific Railway Company, Canadian Pacific Railway Company, Ia> Gérant du Service des Postes et Bagages, Per: W; E.ALLISON, 26S87-S-6-0 W.E.ALLISON.26887-8-6-o Manager, Mail and Baggage Traffic.AVIS DE VENTE NOTICE OF SALE Avis est, par les présentes, donné que tous les Notice is hereby given that all goods received effets reçus avant le premier jour de mai et non previous to the first day of May, 1949, and still réclamés aux bureaux de la \"Canadian Pacific remaining unclaimed in the offices of the \"Cana- Express Company\", à divers endroits des provin- dian Pacific Express Company\" at different ces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse points in the provinces of New Brunswick, Nova et de Québec, seront vendus aux enchères publi- Scotia and Quebec will be sold by Public Auction ques au plus haut enchérisseur par Frank Wad- to the highest bidder by Frank Waddington, dington, encanteur, successeur de D.M.Hender- Auctionneers, successors to D.M.Henderson & son & Company, encanteurs, à 128 ouest, rue King, Company, Auctionneers, at 128 King Street Toronto, Ont., à onze heures du matin, le qua- West, Toronto, Ont., at eleven o'clock in the fore- tnème jour de mai 1950, conformément à la Loi noon on the fourth day of May, 1950, under au- des Chemins de fer du Canada, à moins que les- thority of the Railway Act of Canada, unless dits effets ne soient réclamés et tous les frais payés same shall be called for before that cTate and all avant cette date.charges paid thereon.Montreal, Que., February 14th, 1950.Canadian Pacific Express Company, K.COPEMAN, 26874-7-6-0 Superintendent.Montréal, Que., 14 février 1950.Canadian Pacific Express Company, ,lo_ Le Surintendant, ^6874-7-6 K.COPEMAN. 704 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 25 février 1950, Tome 82, N° 8 Ventes\u2014Loi de faillites Sales\u2014Bankruptcy Act SOUS LA LOI DE FAILLITE Vente à l'enchère publique UNDER THE BANKRUPTCY ACT Public Auction Sale Dans l'affaire de François Champagne, horti- In the matter of François Champagne, horticulteur, St-Georges Est, Co.Beauce, P.Q.culturist, St-Georges-est, Co.of Beauce, P.Q.Avis est par les présentes donné que MERCREDI le 15 MARS 1950 à 10.30 A.M.(heure solaire) seront vendus à la porte de l'Église paroissiale de St-Georges, Co.Beauce, les actifs suivants: 25 lots à bâtir, subdivisions du lot N° 610 de la paroisse de St-Georges Est, Co.Beauce: 1° Les lots numéros un, deux, trois, partie du lot numéro sept, partie du lot numéro huit, partie du lot numéro neuf, partie du lot numéro dix, partie du lot numéro douze, les lots numéros quinze, seize, dix-neuf, vingt, vingt-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente-et-un, trente-deux, trente-trois, trente-cinq et trente-six, de la subdivision du lot numéro six cent dix fraction vingt-huit (610-28-1; 610-28-2; 610-28-3; ptie 610-28-7; ptie 610-28-8; ptie 610-28-9; ptie 610-28-10; ptie 610-28-12; 610-28-15; 610-28-16; 610-28-19; 610-28-20 ; 610-28-21 ; 610-28-22; 610-28-23; 610-28-24; 610-28-25; 610-28-28; 610-28-29; 610-28-30; 610-28-31; 610-28-32; 610-28-33; 610-28-35; 610-28-36;) Avec bâtisses ci-dessus construites, circonstances et dépendances.A distraire cependant: Du lot 610-28-1, la partie appartenant a la Municipalité du Village Est de St-Georges de Beauce.Du lot 610-28-15, la partie appartenant à Pierre Poulin.Du lot 610-28-16, la partie appartenant à Eugène Veilleux.Des lots 610-28-7, 610-28-8, 610-28-9, 610-28-10, 610-28-11 et 610-28-12, la lisière de terrain de 12 pieds de largeur appartenant à Wilfrid Champagne.2° Un emplacement situé en la paroisse de St-Georges de Beauce, faisant partie du lot numéro six cent dix (610) du cadastre de la paroisse de St-Georges en le comté de Beauce, compris dans les bornes et délimitations suivantes: born, au nord-ouest à Wilfrid Champagne; au nord-est à Emile Poirier, au sud-est partie à Emile Poirier et partie à Raoul Boutin; et au sud-ouest aux lots numéros 610-28-12; 610-28-35 et 610-28-36 du plan amendé, d'une partie du cadastre de la paroisse de St-Georges, comté de Beauce, maintenant de la municipalité du village de St-Georges Est.Conditions de vente: comptant.Les actifs ci-dessus peuvent être examinés sur les lieux, samedi le 11 mars 1950, de 9 hrs du matin à midi et de deux heures à 5 heures P.M.Le Syndic, \u2022 LS.-ROBERT RUEL.1ère Avenue, Saint-Georges, Co.Beauce, P.Q.Bureau: 1ère Avenue, St-Georges, Beauce, P.Q.Notice is hereby given that on WEDNESDAY, the 15th of MARCH, 1950, at 10.30 A.M.(Standard Time), the following assets will be sold at the parochial church door of St-Georges, Co.Beauce: 25 building lots, subdivisions of lot No.610 of the parish of St-Georges est, Co.Beauce: 1.Lots numbers one, two, three, part of lot number seven, part of lot number eight, part of lot number nine, part of lot number ten, part of lot number twelve, lots numbers fifteen, sixteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, thirtyrtwo, thirty-three, thirty-five and thirty-six, of the subdivision of lot number six hundred and ten fraction twenty-eight (610-28-1; 610-28-2; 610-28-3; Pt.610-28-7; Pt.610-28-8; Pt.610-28-9; Pt.610-28-10; Pt.610-28-12; 610-28-15; 610-28-16; 610-28-19; 610-28-20; 610-28-21; 610-28-22; 610-28-23; 610-28-24 ; 610-28-25; 610-28-28; 610-28-29; 610-28-30; 610-28-31; 610-28-32; 610-28-33; 610-28-35; 610-28-36;) With buildings thereon erected, circums-stances and dependencies.To be deducted, however: From lot 610-28-1, the part belonging to the municipality of the village East of St-Georges de Beauce.From lot 610-28-15, the part belonging to Pierre Poulin.From lot 610-28-16, the part belonging to Eugène Veilleux; From lots 610-28-7, 610-28-8, 610-28-9, 610-28-10, 610-28-11, and 610-28-12, the strip of land of 12 feet in width belonging to Wilfrid Champagne.2.An emplacement situate in the parish of St-Georges de Beauce, forming part of lot number six hundred and ten (610) on the cadastre for the parish of St-Georges in the county of Beauce, comprised within the following boundaries and limits: bounded to the northwest by Wilfrid Champagne, on the northeast by Emile Poirier; to the southeast partly by Emile Poirier and partly by Raoul Boutin; to the southwest by lots numbers 610-28-12; 610-28-35 and 610-28-36 on the amended plan of part of the cadastre for the parish of St-Georges, county of Beauce, now the municipality of the village of St-Georges-est.Conditions of sale : cash.The above assets may be examined on the.premises on Saturday, March 11, 1950, from 9 o'clock in the morning to twelve, and from two to five o'clock P.M.LS.ROBERT RUEL, Trustee.1st Avenue, Saint-Georges, Co.Beauce, P.Q- Office: 1st Avenue, St-Georges, 26801-6-2-o Beauce, P.Q.26801-6-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 25th, 1950, Vol.82, No.8 705 Province de Québec, district de Montréal, No.67, Cour Supérieure, \"En faillite\".AVIS DE VENTE Dans l'affaire de: Gabriel Heral, marchand, Ste-Hélène de Bagot, cédant autorisé, & Claude Terras, syndic.Avis public est par les présentes donné que l'immeuble suivant, formant une seule et même exploitation, savoir: désignation 10 Un immeuble situé au village de la Paroisse de Ste-Hélène de Bagot, sur le côté sud-ouest de la rue conduisant à la gare du Canadien National, de la contenance de soixante pieds de largeur en front par soixante pieds de profondeur, et de là prenant cent vingt pieds de largeur par cent vingt pieds de profondeur, le tout à la mesure anglaise et plus ou moins, connu et désigné sur le plan et au livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Hélène, comme faisant partie par le chemin public, partie par le terrain décrit au paragraphe suivant et partie par le terrain d'Ovila Bolduc, en profondeur par le terrain ci-après décrit au paragraphe 3, d'un côté partie par le terrain de Ré-nald Lépine et partie par celui décrit au paragraphe suivant, et de l'autre côté par le terrain d'Arthur Laurion, avec bâtisses y érigées.\" A distraire un terrain de la contenance de cinquante pieds de largeur par trente pieds de profondeur, connu et désigné au cadastre officiel de la paroisse de Ste-Hélène comme étant une partie du lot numéro cent trente-neuf (P.139), avec bâtisses, borné en front par le terrain d'Ovila Bolduc, en profondeur par Se terrain présentement vendu, d'un côté par le terrain présentement vendu, et de l'autre côté par une coulée naturelle, lequel terrain distrait appartient audit Ovila Bolduc par l'acte d'échange ci-après mentionné; 2° Une lisière de terrain située au village de la paroisse de Ste-Hélène, ayant front sur la rue qui conduit à la gare du C.N.R.de la contenance de dix pieds de largeur par soixante pieds de profondeur, le tout à la mesure anglaise, connue et désignée au cadastre officiel de la paroisse de Ste-Hélène comme étant une partie du lot numéro cent trente-neuf (P.139) bornée en front par la dite rue, en profondeur et d'un côté par le terrain décrit au paragraphe 1, et de l'autre côté par le terrain d'Ovila Bolduc, sans bâtisses.3 Un terrain ayant la forme d'un triangle rectangle, situé à la profondeur du terrain ci-dessus décrit au paragraphe 1, connu et désigné au cadastre officiel de la dite paroisse de Ste-Hélène comme étant une partie du lot numéro cent trente-neuf (P.139) borné d'un bout au terrain ci-dessus décrit au paragraphe 1 sur une longueur d'environ soixante-dix pieds, du côté sud-est à angle droit sur une largeur de soixante-dix pieds à partir du même lot appartenant à Dame H.Beauregard ou représentants, du troisième côté, sur une longueur d'environ cent dix pieds, à une cours d'eau rejoignant les deux autres côtés, le tout à la mesure anglaise et sans garantie de précision, avec bâtisses y érigées.\" , Seront vendus à la porte de l'église paroissiale de Ste-Hélène, comté Bagot à ONZE heures H avant-midi, MERCREDI, le VINGT-NEUF MARS 1950.Conditions: comptant.Province of Quebec, District of Montreal, No.67, Superior Court \"Sitting in Bankruptcy\".NOTICE OF SALE In the matter of Gabriel Heral, merchant, Ste-Hélène de Bagot, Authorized Assignor, & Claude Perras, trustee.Public notice is hereby given that the following immovables, forming one same and single exploitation, to wit: Designation: 1.An immovable situate in the village of the parish of Ste-Hélène de Bagot, on the southwest side of the street leading to the Canadian National Station, measuring sixty feet in front by sixty feet in depth and thence being one hundred and twenty feet in width by one hundred and twenty feet in depth, the whole English measure and more or less, known and designated on the official plan and in the book of reference for the parish of Ste-Hélène as forming part of lot number one hundred and thirty-nine (Pt.139) bounded in front partly by the public road, partly by the land described in the following paragraph, and partly by the land of Ovila Bolduc, on the depth by the land hereinafter described in paragraph 3, on one side partly by the land of Ronald Lepine, and partly by that described in the following paragraph and on the other side by the land of Arthur Laurion \u2014 with buildings thereon erected.To be deducted a lot of land measuring fifty feet in width by thirty feet in depth known and designated on the official cadastre for the parish of Ste-Hélène as being part of lot number one hundred and thirty-nine (Pt-139)\u2014with buildings \u2014 bounded in front by the land of Ovila Bolduc, on the depth by the land presently sold, and on the other side by a natural hollow (coulée) said deducted lot of land belonging to said Ovila Bolduc, by deed of exchange hereinafter mentioned.2.A strip of land situate in the village of the parish of Ste-Hélène, fronting on the street leading to the C.N.R.station measuring ten feet in width by sixty feet in depth, the whole English measure, known and designated on the official cadastre for the parish of Ste-Hélène as being part of lot number one hundred and thirty-nine (Pt.139) bounded in front by the said street, on the depth and on one side, by the land described in paragraph 1, and oh the other side by the land of Ovila Bolduc,\u2014 without buildings.3.A lot of land having the shape of a right-angled triangle, situate at the depth of the land hereinabove described, in paragraph 1, known and designated on the official cadastre for the said parish of Ste-Hélène as being part of lot number one hundred and thirty-nine (Pt.139) bounded at one end by the land herein above described in paragraph 1, on a le right of about seventy feet, on the southeast side, at right angles, on a width of seventy feet, starting from the same lot, belonging to Dame H.Beauregard or representatives, on the third side, on a lenght of about one hundred and ten feet, by a watercourse meeting the two other sides, the whole English measure and without guarantee of exact measurement,\u2014 with buildings thereon erected.Will be sold at the parochial church door of Ste-Hélène, county of Bagot, at 11 o'clock in the forenoon, on WEDNESDAY, MARCH 29, 1950.Conditions: cash. 706 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 25 février 1950, Tome 82, N° 8 Le procès-verbal et le cahier des charges sont déposés au bureau du syndic pour examen.Cette vente est faite en vertu d'un jugement rendu par le Régistraire du greffe des faillites à Montréal, le 15 février 1950 et suivant les prescriptions de l'article 45-de la Loi de Faillite et avec l'effet du décret.Le Syndic, CLAUDE FERRAS.Bureau de: Perras & Perras, syndics-licenciés, 4 est, Notre-Dame, Montréal.26903-8-2-o Vente par licitation The minutes and list of charges have been filed in the office of the undersigned trustee, for examination.This sale is made in virtue of a judgment rendered by the Registrar of the Bankruptcy Office, at Montreal, on the 15th of February, 1950, and pursuant to the provisions of section 45 of the Bankruptcy Act, having the effect of a Sheriff's Sale.CLAUDE PERRAS, Office of: Trustee.Perras & Perras, Authorized Trustees, 4 Notre-Dame Street East, Montreal.26903-S-2 Sale by Licitation Canada, Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 275 139.Avis est ici donné qu'en vertu d'un jugement rendu par la Cour supérieure séant à Montréal, le 28 décembre 1949, dans cette cause où Anita Lamourcux, fille majeure et usant de ses droits des cité et district de Montréal, est demanderesse, et où Marius Dubreuil, Dame Marguerite Dubreuil-Desroches, épouse contractuellement séparée de biens de Roméo Desroches et ledit Roméo Desroches pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Joseph Dubreuil, Dame Maria Lamoureux-Picard, épouse contractuellement séparée de biens de Orner Picard et ledit Omer Picard pour autoriser son épouse aux fins des présentes, et Melles Lucette Dubreuil et Thérèse Dubreuil, tous deux filles majeures, tous des cité et district de Montréal, sont défendeurs, la licitation des immeubles suivants a été ordonnée, savoir: \"Un emplacement situé dans le quartier Saint-Jacques de la cité de Montréal, étant la partie nord-est du lot numéro cinq cent quatre-vingt-treize (593 ptie) des plan et livre de renvoie officiels dudit quartier Saint-Jacques, contenant soixante-et-cinq pieds de largeur, mesure anglaise, par toute la profondeur qui peut s'y trouver, entre la rue Wolfe et une maison en pierre et brique érigée sur l'arrière partie dudit lot, bornée ladite partie du lot présentement décrite, comme suit, savoir: en front par la rue Wolfe, en arrière par Jadite maison de pierre et brique et la lisière de terre ci-après décrite sur laquelle elle est érigée, appartenant en usufruit à' Thomas Lamoureux ou représentants, du côté nord-ouest par une partie du lot numéro cinq cent quatre-vingt-quatorze desdits plan et livre de renvoi officiels, la propriété d'Olympe Mathieu ou représentants; avec une maison en bois divisée en quatre logements portant les numéros 1188, 1190, .1194 et 1198 de ladite rue Wolfe et autres bâtisses sus-érigées; auquel emplacement doit être ajoutée une lisière de douze pieds de profondeur par toute la largeur dudit lot numéro cinq cent quatre-vingt-treize, laquelle lisière fait aussi partie de ce lot et est bornée du côté nord-est par la partie sus-décrite du lot numéro cinq cent quatre-vingt treize qui est bornée en front par la rue Wolfe, en arrière au sud-ouest par une autre partie du lot numéro cinq cent quatre-vingt-treize, du côté nord-ouest, par une partie du lot numéro cinq cent quatre-vingt-quatorze, et du côté sud-est par une partie dudit lot numéro cinq cent quatre vingt-douze, sur laquelle lisière est érigée une partie de la dite maison en pierre et brique, Canada, Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.275 139.Notice is hereby given that in virtue of a judgment rendered by the Superior Court, sitting at Montreal, on December 28, 1949, in a case wherein Anita Lamoureux, spinster and in use of her rights of the city and district of Montreal, is plaintiff; and wherein Marius Dubreuil, Dame Marguerite Dubreuil Desroches, wife separate as to property by marriage contract of Roméo Desroches and the said Roméo Desroches to authorize his wife for the purposes hereof, Joseph Dubreuil, Dame Marie Lamoureux-Picard, wife separate as to property by marriage contract of Orner Picard, and said Omer Picard, to authorize his wife for the purposes hereof, and the Misses Lucette Dubreuil and Thérèse Dubreuil, both spinsters, both of the city and district of Montreal, are defendants, the licitation of the following immovables has been ordered, to wit: \"An emplacement situate in Saint-James' ward in the city of Montreal, being the northeast part of lot number five hundred and ninety-three, (Pt.593) on the official plan and in the book of reference for said Saint James' ward, measuring sixty-five feet in width, English measure, by the whole of the depth which there may be between Wolfe Street, and a stone and brick house erected on the rear part of said lot, said part of lot hereby described bounded as follows, to wit: in front by Wolfe Street, in rear by the said stone and brick house and the strip of land hereinafter described, upon which it is erected, belonging usufructually to Thomas Lamoureux or representatives, on the northwest by part of lot number five hundred and ninety-four of said official plan and book of reference, property of Olympe Mathieu or representative; with a wooden houses divided into four dwellings bearing numbers 1188, 1190, 1194, and 1198, of said Wolfe Street, and other buildings thereon erected; to which emplacement there must be added a strip of twelve feet in depth by the whole width of lot number five hundred and ninety-three, said strip also forming part of this lot and is bounded on the northeast side by the above described part of lot number five hundred and ninety-three, winch is bounded in front by Wolfe Street, in rear, 'on the southeast by another part of lot number five hundred and ninety-three, on the northwest side by part of lot number five hundred and ninety-four and on the southeast by part of said lot number five hundred and ninety-two, upon which strip is erected a part of said stone ana brick house, sais strip of land and said stone QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 25th, 1950, Vol 82, No.8 707 laquelle lisière de terre et la dite maison en pierre et brique, ont été léguées^en usufruit à feu Thomas Lamoureux et en propriété à d'autres personnes par feu Eugène Lamoureux et dame Henriette Grenon, son épouse, tant que ladite maison ne sera pas détruite par le feu, par vétusté ou par quelqu'autre accident, alors que ladite lisière de terre devra être réunie à la partie ci-dessus décrite en premier lieu, dudit lot numéro cinq cent quatre-vingt-treize et appartiendra aux propriétaires d'icelles.Ainsi que le tout se trouve actuellement, avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées auxdits immeubles.\" Les immeubles susdésignés seront vendus en bloc à l'enchère, et adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur le VINGT-DEUXIEME jour de MARS 1950 à DIX heures et DEMIE de l'avant-midi, par cette Cour, au Palais de Justice à Montréal, à la chambre 31, ou dans toute autre chambre dudit Palais que la Cour désignera aux fins de ladite vente aux enchères, le tout sujet aux clauses, charges et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au Greffe de cette Cour dans le présent dossier.Toute opposition afin d'annuler, afin de charge ou afin de distraire à ladite licitation devra être déposée au Greffe du Protonotaire au moins douze jours avant la date fixée pour ladite vente et adjudication, et toutes oppositions afin de conserver devront être déposées dans les six jours après l'adjudication: et à défaut par les intéressés de déposer leurs dites oppositions dans les délais prescrits, ils seront forclos de le faire, conformément, à la loi.Un dépôt de deux mille dollars ($2,000.00) devra être fait par tout enchérisseur avant que son offre et enchère soit reçue à ladite vente.Montréal, le 10 février 1950.L'Avocat de la demanderesse, RENÉ DROUIN.10 est, St-Jacques, Montréal.26841-7-2-o and brick house were bequeathed in usufruct to the late Thomas Lamoureux and in ownership to other persons by the late Eugène Lamoureux and Dame Henriette Grenon, his wife, as long as the said house shall not have been destroyed by fire, by decay or by some other accident, at which time the said strip of land shall be joined to the part hereinabove firstly described of said lot number five hundred and ninety-three and shall belong to the owners of same.As the whole presently subsists, with the active and passive, apparent or unapparent servitudes attached to the said immovables.\" The above described immovables will be sold \"en bloc\" by auction, and adjudged to the highest and last bidder on the TWENTY-SECOND day of MARCH, 1950, by the said Court, in the Court House, district of Montreal, at HALF PAST TEN o'clock in the forenoon, in Room 31, or in any other room of the said Superior Court, designated by the Judge for the purpose of the said sale, subject to the clauses, charges and conditions indicated in the list of charges filed in the Office of the Prothonotary of the said Court, in the present case.Any opposition to annul, to secure charges or to withdraw to be made to the said licitation must be filed in the Office of the Prothonotary at least twelve days before the date fixed for the said sale and adjudication and any opposition for payment must be made within the six days following the adjudication, and failing the parties to file the said opposition in the delay prescribed they shall be^foreclosed from so doing according to law.A deposit of two thousand dollars ($2,000 00) shall be required from each and every bidder before his offer and bid may be received at the said sale.Montreal, February 10, 1950.RENÉ DROUIN, Attorney for the plaintiff.10 St.James Street East, Montréal.'26841-7-2 VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.ARTHABASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure\u2014district d'Arthabaska.Arthabaska, à savoir: \\ \"D OGER BOISVERT, N° 5743 { ouvrier, domicilié à St-Norbert, district d'Arthabaska, demandeur; vs ROSARIO LEBRUN, résidant à St-Paul de Chester, district d'Arthabaska, défendeur.Comme appartenant au défendeur; Une terre dans la dite paroisse de St-Paul de Chester, faisant partie du lot numéro vingt du dixième rang du canton de Chester, connue et désignée au cadastre officiel de la paroisse de St-Paul, comté d'Arthabaska, comme étant le numéro trois cent quatre vingt quatre (384), de la contenance de trois arpents de largeur, plus ou moins, sur la profondeur du rang, borné au nord-ouest à la ligne de la paroisse de St-Chris-tophe, au sud-est à Eugène Houde, avec les bâtisses dessus contruites, mais la dite terre n'a pas la même largeur près du cordon du onzième nuîg» et en outre à en distraire, s'il y a lieu la SHERIFF'S SALES PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LAND and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ARTHABASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Superior Court\u2014District of Arthabaska Arthabaska, to wit : \\ \"D OGER BOISVERT, No.5743 \\ -^workman, domiciled at St-Norbert, district of Arthabaska, plaintiff; vs ROSARIO LEBRUN, residing at St-Paul de Chester, district of Arthabaska, defendant.As belonging to the defendant: A farm in the said parish of St-Paul de Chester, forming part of lot number twenty of the tenth range of the township of Chester, known and designated on the official cadastre for the parish of St-Paul, county of Arthabaska, as being number three hundred and eighty-four (384), containing three arpents in width, more or less, by the depth of the range, bounded on the northwest by the line of the parish of St-Christophe, on the southeast by Eugène Houde, with the buildings thereon erected, but the said farm has not the same width near the \"cordon\" of the eleventh range, and moreover to be deducted 708 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 25février 1950, Tome 82, N° 8 minime partie occupée par les représentants de feu Ferdinand Simon eau.Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de St-Paul de Chester, comté d'Arthabaska, le SEPTIEME jour de MARS 1950, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, MAURICE MAHEU.Arthakaska, 27 janvier 1950 26762-5-2-o [Première insertion: 4 février 1950] Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure \u2014 District d'Arthabaska Arthabaska, / T OUIS CLOUTIER, commer-à savoir: < çant de la ville de Victoria-No.6200.I ville, demandeur, vs LÉO BER-NIER, cultivateur de St-Rémi de Tingwick, défendeur.Comme appartenant au défendeur: Une terre faisant partie du premier lot du neuvième rang du canton de Tingwick, contenant quatre arpents de front, plus ou moins, sur la profondeur du lot, connue et désignée au cadastre officiel du canton de Tingwick comme étant la moitié sud-ouest du numéro huit cent soixante (N° 860) et l'arpent et demi nord-est du numéro huit cent soixante et un (N° 861) prenant des deux côtés à Conrad Dion, avec bâtisses dessus construites.Pour être vendue à la porte de l'église de la paroisse de St-Rémi de Tingwick, comté d'Arthabaska, le VINGT-HUITIEME jour de MARS 1950, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, MAURICE MAHEU.Arthabaska, 21 février 1950.26907-8-2-o [Première insertion: 25 février 1950] therefrom, if needs be, the small part occupied by the representatives of the late Ferdinand Simoneau.To be sold, at the church door of the parish of St-Paul de Chester, county of Arthabaska, on the SEVENTH day of MARCH, 1950, at TWO o'clock in the afternoon* MAURICE MAHEU, Sheriff's Office, Sheriff.Arthabaska, January 27, 1950.26762-5-2 [First insertion: February 4, 1950] Fieri Facias de Bonis et de Terris Superior Court\u2014District of Arthabaska, Arthabaska, (1 OUIS CLOUTIER, trader, of to wit: < *^ the town of Victoriaville, No.6200 (plaintiff, vs LÉO BERNIER, farmer, of St-Rémi de Tingwick, defendant.As belonging to the defendant: .A farm forming part of the first lot of the ninth range of the township of Tingwick, measuring four arpents in front, more or less, by the depth of the lot, known and designated son the official cadastre for the township of Tingwick, as being the southwest half of lot number eight hundred and sixty (No/860) and one and one half arpent northeast of number eight hundred and sixty-one (No.861), adjoining on both sides Conrad Dion \u2014 with'buildings thereon erected.To be sold at the church door of the parish of St-Rémi de Tingwick, county of Arthabaska, on the TWENTY-EIGHTH day of MARCH, 1950, at TWO o'clock in the afternoon.MAURICE MAHEU, Sheriff's Office, Sheriff.Arthabaska, February 21, 1950.26907-8-2 [First insertion: February 25, 1950] BEDFORD Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada, (1 TNITÊD AUTO Province de Québec J ^ PARTS (Granby) District de Bedford, \\ LIMITED, corporation lé-N° 3064 ' gaiement constituée et ayant sa principale place d'affaires à Granby, district de Bedford, demanderesse, vs DAME LOUISE ALPHONSINE LAFRENIERE, épouse séparée de biens de Gustave Bertrand, et ledit Gustave Bertrand, garagiste, tous deux ci-devant de Eastman, district de Bedford, ladite Louise Alphonsine Lafrenière y ayant fait affaires seule, comme marchande publique avec l'autorisation de son mari sous le nom de EASTMAN GARAGE, et tous deux maintenant de la cité et du district de Montréal, défenderesse.Comme appartenant à la défenderesse: \"Un immeuble étant le N° 1126 du cadastre aux plan et livre de renvoi officiel pour le canton de Bolton, avec bâtisses dessus érigées.\" Pour être vendu à la porte de l'église de St-Edouard d'Eastman, district de Bedford, MERCREDI, le VINGT-NEUF MARS 1950, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, A.ST-MARTIN.Palais de Justice Sweetsburg, Que., 'l7 février 1950.26899-8-2-0 [Première insertion: 25 février 1950] GASPÉ Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Québec Québec, j XJOEL BÉGIN INC.corps poli-No.59185 \\ *V tique et incorporé, ayant sa BEDFORD Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada, (1 TNITED AUTO Province of Quebec, J ^ PARTS (Granby) District of Bedford, J LIMITED, a body politic No.3064 \\ and corporate, having its principal place of business at Granby, district of Bedford, plaintiff, vs DAME LOUISE ALPHONSINE LAFRENIERE, wife separate as to property of Gustave Bertrand, and the said Gustave Bertrand, garage-keeper, both heretofore of Eastman, district of Bedford, the said Louise Alphonsine Lafrenière, there having carried on business alone, as public merchant, with her husband's authorization, under the name of EASTMAN GARAGE, and both now of the city and district of Montreal, defendant.As belonging to the defendant: \"An immovable being No.1126, on the official cadastral plan and in the book of reference for the township of Bolton \u2014 with buildings thereon erected.\" To be sold at the church door of St-Edouard d'Eastman, district of Bedford, on WEDNESDAY, the TWENTY-NINTH of MARCH, 1950, at TWO o'clock in the afternoon.A.ST-MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Court House, Sweetsburg, Que., February 17, 1950 20899-8-2 [First insertion : February 25, 1950] GASPÉ Fieri Facias de Bonis et de Terris Superior Court \u2014 District of Quebec Quebec, J XJOEL BEGIN INC.a body F No.59185 } +y tic and corporate, having QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 26th, 1950, Vol.82, No.8 709 nrincipale place d'affaires en la cité de Levis, demanderesse, vs J.MAURICE NORMAND, résidant à d'Aiguillon, Co.Gaspé, P.Q., défendeur.\"Une propriété située une partie numéro 14 et l'autre numéro 15 du cadastre officiel premier rang, Canton Cap des Rosiers.\" Pour être vendue à la porte de l'église de Cap-aux-Os, comté de Gaspé Nord, JEUDI, le TRENTE de MARS 1950, à ONZE heures de Pavant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, M.J.PURLONG.Percé, P.Q., le 17 février 1950.26900-8-2-o [Première insertion: 25 février 1950] principal place of business in the city of Levis, plaintiff; vs J.MAURICE NORMAND, residing at d'Aiguillon, Co.Gaspé, P.Q.defendant.A property situate one part number 14 and the other number 15 of the official cadastre for the first range, township Cap des Rosiers.To be sold at the church door of Cap-aux-Os, county of Gaspé North, on THURSDAY, the THIRTIETH of MARCH, 1950, at ELEVEN o'clock in the forenoon.M.J.FURLONG, Sheriff's Office, Sheriff.Percé, P.Q., February 17, 1950.26900-8-2 [First insertion: February 25, 1950] MONTREAL Fieri Facias de Terris C.S.District de Montréal Montréal, à savoir: j p«OINEAU & BOUS-N° 276280.\\ ^ QUEST, CIE, LTÉE, demanderesse; vs ARTHUR VACHON & AL, défendeurs.« Comme appartenant à Arthur Vachon, l'un des défendeurs.Deux propriétés sises et situées sur la rue Delaroche à Montréal dit district; connues et désignées sous les Nos.quatre-vingt-quatorze et quatre-vingt-quinze de la subdivision officielle du lot originaire N° deux cent vingt-six (226-94, 95) aux planjet livre de renvoi officiels de la paroisse du Sault au Récollet, et sur les lots connus et désignés sous les Nos.trois cent cinquante et un et trois cent cinquante-deux de la subdivision officielle du lot originaire N° ceux cent vingt-cinq A (225A-351, 352) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse du Sault-au-Récollet, avec toutes les bâtisses dessus érigées et notamment deux propriétés et leurs dépendances portant les Nos, civiques 10125,10127,10129 et 10131, rue Delaroche.Pour être vendues, à mon bureau, en la cité de Montréal, le DIXIEME jour de MARS prochain, à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, CAISSE & HURTEAU.Montréal, 1er février 1950.26721-5-2-o-x [Première insertion: 28 janvier 1950 est nulle] [Première insertion: 4 février 1950] MONTREAL Fieri Facias de Terris S.C.District of Montreal Montreal, to wit: j f^OINEAU & BOUS-No.276280 \\ ^ QUEST, CIE, LTÉE-plaintiff; vs ARTHUR VACHON & AL, defendants.As belonging to Arthur Vachon, one of the defendants: Two properties lying and situate on Delaroche street, in Montreal, said district; known and designated as numbers ninety-four and ninety-five of the official subdivision of original lot number two hundred and twenty-six (226-94, 95) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Sault au Récollet, and on the lots known and designated as numbers three hundred and fifty-one and .three hundred and fifty-two of the official subdivision of original lot number two hundred and twenty-five-A (225-A 351, 352) on the official plan and in the book of reference for the parish of Sault-au-Récollet, with all the buildings thereon erected and in particular twro properties and their dependencies, bearing civic Nos.10125, 10127, 10129 and 10131 Delaroche street: To be sold, at my office, in the city of Montreal, on the TENTH day of MARCH next, at TEN o'clock in the forenoon.CAISSE & HURTEAU, Sheriff's Office, Sheriff.\u2022Montreal, February 1st, 1950.26721-5-2-o-x [First insertion: January 28, 1950 is null] [First insertion: February 4, 1950] Fieri Facias de Terris Cour de Magistrat\u2014District de Montréal Montréal, à savoir: j \\\\ 7TLLIAMD.MAHER, N° 115910.| vv demandeur, vsSEN-NEVILLE COUNTRY CLUB INC., défenderesse.Un emplacement ayant front sur le Morningside Drive, en la paroisse de Ste-Anne, comté de Jacques-Cartier et composé: 1.Des lots numéros 460, 466, 467, 468, 469, 474, 475, 476 et 477 du lot originaire numéro 21 aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Anne, comté de Jacques-Cartier.2.Dune partie du lot originaire N° 21 des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Anne, comté de Jacques-Cartier, mesurant 95 pieds de largeur par 163 pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, bornée au sud-est par une autre partie du lot N° 21, étant la continuation d'une rue portant le N° 21-432 et connue présentement comme étant le Morning-81^e Drive, au nord-ouest par une partie non-subdivisée du lot No 21, au sud-ouest par une Partie des lots 21-973, 21-972, 21-971, 21-970 et Fieri Facias de Terris Magistrate's Court\u2014District of Montreal Montreal to wit: j \\\\ 71LLIAM D.MAHER, No.115910.J VV Plaintiff vs SENNE-VILLE COUNTRY CLUB INC., Defendant.\"An emplacement fronting on Morningside Drive, in the Parish of Ste Anne, County of Jacques-Cartier, and composed of.1.Lots Numbers 460, 466, 467, 468, 469, 474, 475, 476 and 477 of original lot Number 21, of the Official Plan and Book of Reference of the Parish of Ste.Anne, County of Jacques-Cartier.2.Part of original lot No.21, of the Official Plan and Book of Reference of the Parish of Ste Anne, County of Jacques-Cartier, measuring 95 feet in width by 163 feet in tlepth, english measure more or less, bounded to the South East by another part of lot No.21 being the continuation of a street bearing No.21-432 and now known as Morningside Drive, to the North-West by an unsubdivided part of Lot No.21, to the South-West by part of lots 21-973, and 21-972, 21-971, 21-970 and part of 21-969 and to the 710 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 février I960, Tome 82, N° 8 une partie de 21-969, et au nord-est par les lots 21-460 et 21-461 desdits plan et livre de renvoi officiels.Pour être vendu à mon bureau, en la cité de Montréal, le DIXIEME jour de MARS prochain, à ONZE heures du matin.Le Shérif, Bureau du shérif, CAISSE & HURTEAU.Montréal, 1er février 1950.26777-5-2 [Première insertion: 4 février 1950] Fieri Facias de Terris C.S.District de Montréal & Montréal, à savoir: ( /MOINEAU & BOUS-No.279052 JVJ QUET CIE, LIMITÉE, demanderesse, vs G.ROBICHAUD, défendeur.\"Une propriété ayant front sur la rue Springfield, à Greenfield Park, Province de Québec, connue et désignée comme étant la partie nord-ouest du lot N° 47 de la subdivision officielle du lot originaire N° deux cent trente-neuf (239-Ptie N.O.47) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Antoine de Longueuil, mesurant 48 pieds de largeur sur l'avenue Springfield par 192 pieds de profondeur, mesure anglaise plus ou moins.Borné ledit emplacement comme suit: en front par l'avenue Springfield, en profondeur par une partie du lot N° 339-52 dudit cadastre, un côté au nord-ouest par le lot no.deux cent trente-neuf-quarante-sept-un du dit cadastre et au sud-est par une autre partie du lot no.239-47 dudit cadastre avec toutes les bâtisses dessus érigées et plus spécialement une maison et ses dépendances portant le no.civique 18 avenue Springfield, à Greenfield Park, Province de Québec.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Chambly, à Longueuil, le TRENTIEME jour du mois de MARS prochain, à ONZE heures de l'avant-midi.» ' Le Shérif, ' Bureau du Shérif, CAISSE & HURTEAU Montréal, 21 février 1950.26901-8-2-O [Première insertion: 25 février 1950] QUÉBEC Fieri Facias Québec, à savoir: / T ALPHONSE DUBOIS, N° 58-064.
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.