Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 23 (no 21)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1953-05-23, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 85, N° 21 1699 Vol.85, No.21 \t\t .*\t\t \t\t1 \t\t i\t\t- * Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de -a province (14 Geo.VI.ch.?) Flag of the Province of Québec adopted by the Act rejpecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE-DE QUEBEC Québec, samedi 23 mai 1953 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements P Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, May 23rd, 1953 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested paTty shall'then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe.Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 1700 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 mai 1953, Tome 86, N° 21 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi-à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 80 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les- chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: .Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.33898 \u2014 1-52 Lettres patentes receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each., Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per ear N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of then edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.33898 \u20141-52 Letters Patent Alexander & Associates (Quebec) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Riehelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du septième jour d'avril 1953.constituant en corporation : Raymond Leboeuf, avocat, Gisèle Behocaray, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, et Myrto Brasseur, secrétaire, de St-Ï^ustache, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchands d'obligations souscripteurs à forfaits, courtiers de placements et d'actions, sous le nom de \"Alexander & Associates (Quebec) Limited\", avec un capital de SI 0,000 divisé en 10,000 actions de 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 266 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Alexander & Associates (Quebec) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941.bearing date the seventh day of April, 1953.incorporating: Raymond Leboeuf.lawyer, Gisèle Behocaray, secretary, both of the city of Montreal, judicial district of Montreal, and Myrto Brasseur, secretary, of St.Eus-tache, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To carry on the business of bond dealers, underwriters, investment brokers and share brokers, under the name of \"Alexander & Associates (Quebec) Limited\", with a capital stock of $10,000 divided into 10,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at 266 St.James St., West, Montreal, judicial district of Montreal.\\ QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol.85, No.21 1701 Daté du bureau du Procureur général, ce Dated at the office of the Attorney General, septième jour d'avril 1953.this seventh day of April, 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 34845 L.DÉSILETS.34845-0 Deputy Attorney General.Alex Tousignant Limilde Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenaut-gouvemeur de ia province de Québec, représenté par M.C La-Richelière, conformément a l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du neuf avril 1953, constituant en corporation: Jacques Décary, avocat, de Dorval, Georges Bilodeau, avocat, de Montréal-Nord, Neil L.King, avocat, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie de la construction, sous le nom de \"Alex Tousignant Limitée\", avec un capital de $100,000 divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la' compagnie sera à 2251, rue Gilford, Montréal, district judiciaire de Montreal.Daté du bureau du Procureur général le neuf avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34845 L.DÉSILETS.Alex Tousignant Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the ninth day of April, 1953, incorporating: Jacques Décary, advocate, of Dorval, Georges Bilodeau, of Montreal-North, Neil L.King, advocate, of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the building trade, under the name of \"Alex.Tousignant Limitée\", with a capital stock of $100,000 divided into 1,000 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 2251 Gilford Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34845 Deputy Attorney General.All Nations Book and Film Service Ltd.AH Nations Book and Film Service Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément ù l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dixième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Etienne de Bode, importateur, Eva Berzy de Bode, commis, épouse séparée de biens d'Etienne de Bode et dûment autorisée par son dit mari aux fins des présentes, Romain Bédard, comptable agréé, tous des cité et district, judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et faire le négoce de livres, disques de phonographes, films, musique en feuilles, revues, accessoires électriques, sous le nom de \"AH Nations Book and Film Service Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34845 L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelièrc, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the tenth day of April, 1953, incorporating: Etienne de Bode, importer, Eva Berzy de Bode, Clerk, wife separate as to property of Etienne de Bode, and duly authorized by her said husband for the purpose of these presents, Romain Bédard, chartered accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with books, phonograph records, films, sheet music, magazines, electrical appliances, under the name of \"All Nations Book and Film Service Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided in 1,000 common shares of $10.each and 300 preferred shares of $100 each.The lread office of the Company will be at the city of Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this tenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34845-0 Deputy Attorney General.Association of Shirt and Pyjama Manufacturers of the Province of Quebec Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du seize avril 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Jack Moroff, Geralu White, Reginald Henry Harrison, manufacturiers, de ville Mont-Royal, Jack Blumen-thal, manufacturier, de la ville de Hampstead, Moses Levitt, David Yosipovitch, manufacturiers de la cité d'Outremont, Louis Vaintrub, Samuel Vaintrub, Albert Gould, Nathan Neme- Association of Shirt and Pyjama Manufacturers of the Province of Quebec Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière.in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the sixteenth day of April, 1953, incorporating without share capital : Jack Moroff, Gerald White, Reginald Henry Harrison, manufacturers, of the town of Mount Royal, Jack Blumenthal, manufacturer, of the Town of Hampstead, Moses Levitt, David Yosipovitch, manufacturers, of the city of Outremont, Louis Vaintrub, Samuel Vaintrub, Albert Gould, Na- 1702 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 mai 1953, Tome 85, N° 21 roff, Moses Miller, Saul Miller, Moses Grover, Sam Krupp.manufacturiers, de Montreal, tous du district judiciaire do Montréal, pour les objets suivants: Grouper en une organisation commune des individus, firmes, compagnies à fonds social, associations et corporations qui s'occupent de la fabrication de chemises et pyjamas et des industries connexes dans la province de Québec, sous le nom de \"Association of Shirt and Pyjama Manufacturers of the Province of Quebec\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $25.000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.E.CÀNTIN.Astor Agencies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Licuterwrnt-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière.conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941.des lettres patentes en date du onze avril 1953.constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat .et conseil en loi de la Reine, Ethel Yussem, secrétaire, de la cité de Montréal, et Theodore H.Shapiro, avocat, de ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger toutes sortes d'affaires d'une agence, trouver des placements, exercer le commerce comme courtiers et agents de manufacturiers, sous le nom de \"Astor Agencies Ltd.\", avec un capital de 820,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.E.CANTIN.Beauce Carnaval Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.*1941, des lettres patentes, en date du quinze avril 1953, constituant en corporation : Florian Vallée, propriétaire de jeux mécaniques.Napoléon Vallée, organisateur de sports, Cécile Ui.net-Vallée, ménagère, épouse contractuelle-ment séparée de biens de Florian Vallée, tous de Saint-Georges de Beauce, district judiciaire de Beauce, pour les objets suivants: Opérer des jeux mécaniques servant à l'amusement et à la distraction du public, sous le nom de \"Beauce Carnaval Inc.\", avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Georges de Beauce, district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du Procureur général le quinze avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.E.CANTIN.than Nemcroff, Moses Miller, Saul Miller, Mqses Grover, Sam Krupp, manufacturers, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To enter into a common organization of individuals, firms, joint stock companies, associations and corporations, engaged in the shirt and pyjama manufacturing and allied industries in the Province of Quebec, under the name of \"Association of Shirt and Pyjama Manufacturers of the Province of Quebec\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is 825,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixteenth dav of April, 1953.C.E.CANTIN, 34845-0 Acting Deputy Attorney General.Astor Agencies Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q.1941, bearing date the eleventh day of April, 1953, incorporating: Joseph Shapiro, advocate and Queen's Counsel, Ethel Yussem, secretary, of the City of Montreal, and Theodore II.Shapiro, advocate, of the town of Mount Royal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To transact all kinds of agency business, to find investment, to carry on business as brokers, and manufactuers' agents, under the name of \"Astor Agencies Ltd.\", with a capital stock of 820,000 divided into 200 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of ApriL 1953.C.E.CANTIN, 34845-o Acting Deputy Attorney General.Beauce Carnaval Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of April, 1953, incorporating: Florian Vallée, proprietor of mechanical games.Napoléon Vallée, sports organizer, Cécile Binet-Vallée, housewife, wife separate as to property by marriage contract, of Florian Vallée.all of Saint-Georges de Beauce, judicial district of Beauce, for the following purposes: ^ Tovoperate mechanical games to be used for the amusement and distraction of the public, under the name of \"Beauce Carnaval Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Georges de Beauce, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of April, 1953.C.E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol.85, No.21 1703 Beaulicu & Lcbel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, représenté par M.C.La-Ricbelièrc, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quatorze avril 1953, constituant en corporation: Emé.Lacroix, c.r., avocat, de ville Mont-Royal, Lucien Thouin, avocat, Paula Boisvert, sténographe, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme contracteur, constructeur général, sous le nom de \"Beaulicu & Lebcl Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatorze avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.E.CANTIN.Bcanlieu & Lcbel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourteenth day of April, 1953, incorporating: Emé.Lacroix, Q.C., advocate, of the town of Mount Royal, Lucien Thouin, advocate, Paula Boisvert, stenographer, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as contractor, general constructor, under the name of \"Beaulicu & Lebcl Inc.\", with a capital stock of $20.000 divided into 2.000 shares of $10 each.The head office of the company 'will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the fourteenth day of April, 1953.C.E.CANTIN, -34845 Acting Deputy Attorney General.Beaurivage & Frères Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-' Richelière, conformément à .l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt avril 1953, constituant en corporation: Jean-Paul Massicotte, André Daviault, avocats, Alain Voizard, notaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux, constructeurs, sous le nom de \"Beaurivage .& Frères Limitée\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 10 est, rue Saint-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.E.CANTIN.Beaurivage & Frères Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twentieth day of April, 1953, incorporating: Jean-Paul Massicotte, André Daviault.advocates, Alain Voisard, notary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors, builders, under the name of \"Beaurivage & Frères Limitée\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at 10 Saint-James Street, East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of April, 1953.C.E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Canadian Welbilt Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-septième jour de mars 1953.constituant en corporation : Jessie McWatters, de Verdun, Kay Katz, de la cité de Montréal, toutes deux secrétaires, et Mauricc-J.Garmaise, notaire, de la cité de Montréal» tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de poêles, réfrigérateurs, lessiveuses, et séchoirs, accessoires produits et dispositifs électriques, sous le nom de \"Canadian Welbilt Company\", avec un capital de $150,000 divisé en 750 actions ordinaires de $100 chacune et 750 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-septième jour de mars 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.E.CANTIN.Canadian Welbilt Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-seventh day of March, 1953, incorporating: Jessie McWatters.of Verdun, Kay Katz, of the city of Montreal, both secretaries, and Maurice-.!.Garmaise, notary, of the city of Montreal, all in the judicial-district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in stoves, refrigerators, washing machines and dryers, electric accessories, products and appliances, under the name of \"Canadian Welbilt Company\", with a capital stock cf 8150,000 divided into 750 common shares of 8100 each and 750 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh dav of March.1953.C.E.CANTIN, 34845-0 Acting Deputy Attorney General. 1704 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 mai 1953, Tome 85, N° 21 Dale Sportswear Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du onzième jour d'avril 1953, constituant en corporation Harold S.Freeman.Abraham H.J.Zaitlin, tous deux avocats, Theresa Murray, secrétaire, tous des cité et district de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers et marchands de vêtements et articles vestimentaires, coiffures et chaussaures.sous le nom de \"Dale Sportswear Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce onzième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.E.CANTIN.Dcpclteau Automobile Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en (late du sept avril 1953, constituant en corporation: .T.-Emery Phaneuf, avocat, conseil de la Reine, Hollande Dozdis, comptable, tous deux de la cité de Montréal, et Robert Turgeon, avocat, de la cité d'Outremont, tous du diAtridt judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter le commerce d'automobiles, moteurs, accessoires, pièces et toutes sortes de machineries; gérer et exploiter des garages; faire le commerce de ferronnerie et quincaillerie, sous le nom de \"Depelteau Automobile Inc.\".avec un capital de $40,000 divisé en 100 actions communes d'une valeur au pair de $100 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le sept avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34845-o L.DÉSILETS.DeSales Uranium Mining Corporation (Libre de responsablité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec,.représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dixième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Henri-Paul Lemay, Bernard LeBel, Georges Bilodeau, avocats de Montréal, Paul-Édouard Ross, avocat, de Verdun, Jacques De-cary, avocat de Strathmore, Ghislaine Gagné, secrétaire, Marcelle Frizzle, épouse légalement séparée d'Arnold Frizzle, tous deux de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des rechercher pour découvrir des mines et des minerais et les négo- Dalc Sportswear Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity \"with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eleventh day of April, 1953, incorporating: Harold S.Freeman, Abraham H.J.Zaitlin, both advocates, Theresa Murray, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufactyrers and dealers in clothing and wearing apparel, head and footwear, under the name of \"Dale Sportswear Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of $100 each, and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Mont-treal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of April, 1953.C.E.CANTIN, 34845-o Acting Deputy Attorney General.Depelteau Automobile Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued bythe Lieutenant-Governor of the Province of Quebecv represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventh day of April, 1953, incorporating: J.Emery Phaneuf, advocate, Queen's Council, Rollande Dozois, accountant, both of the city of Montreal, and Robert Turgeon, advocate, of the city of Outre-mont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in automobiles, motors, accessories, parts and all kinds of machinery,manage and operate garages; to négociate in iron and hardware, under the name of \"Depelteau Automobile Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 100 common shares of a par value of $100 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34845 Deputy Attorney General.DeSales Uranium Mining Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the tenth day of April, 1953, incorporating: Henri-Paul Lemay, Bernard LeBel, Georges Bilodeau, advocates, of Montreal, Paul-Edouard Ross, advocate, of Verdun, Jacques Decary, advocate, of Strathmore, Ghislaine Gagné, secretary, Marcelle Frizzle, wife legally separated from Arnold Frizzle, both of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals, and deal with the same, under the name of \"De- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 2Srd, 1953, Vol.85, So.21 1705 cier, sous le nom de \"DeSalcs Uranium Mining Corporation\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de $4,000,000 divisé en 4,000,000 d'actions d'une valeur au pair de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-xième jour d'avril 1953.L'Assistant-procu reu r général, 34845 « L.DÉSILETS.Dominion File Co.Ltd.- Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du ooze avril 1953, constituant en corporation : Wolf Koopferstock, marchand, Surcka Wasser-man, secrétaire, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, Jacqueline Roberge, sténographe, de Rosemere, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Exercer tous ou aucun des commerces d'imprimeurs, relieurs, manufacturiers et marchands en gros de toutes sortes d'articles de librairie, reliures et livres, sous le nom de \"Dominion File Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 3,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.E.CANTIN.Dufresne et Bergeron Compagnie Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du dix avril 1953, constituant en corporation : Joseph-Adolphe Dufresne, industriel, Lorenza Rouleau,' ménagère, épouse séparée de biens de Joseph-Adolphe Dufresne, Hubert Bergeron, commerçant, et Lucille Lemay, ménagère, épouse séparée de biens de Hubert Bergeron, tous de Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchands de grain, d'instruments aratoires, d'éleveurs d'animaux de ferme et d'animaux à fourrure, sous le nom de \"Dufresne et Bergeron Compagnie Limitée\" avec un capital de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le dix avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.-E.CANTIN.E.W.Caron & Co.Ltd.E.W.Caron & Cie Ltée .Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Sales Uranium Corporation\" (No Personal Liability), with a capital stock of $4,000,000.divided into 4,000,000 shares of a par value of $1.each.The shareholders shall incur no personal liability in excess of, the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this tenth dav of April, 1953.L.DÉSILETS, 34845-0 Deputy Attorney General.Dominion File Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eleventh day of April, 1953, incorporating: Wolf Koopferstock, merchant, Sureka Wasserman, secretary, both of the city and judicial district of Montreal, Jacqueline Roberge, stenographer, of Rosemere, in the judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To carry on all or any of the businesses of printers, book binders, manufacturers and wholesalers of all kinds of stationery supplies, bindings, books, under the name of \"Dominion File Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000 aivided into 500 common shares of $10, each, and 3,500 preferred shares of $10.each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eleventh day of April, 1953.C.E.CANTIN, 34845-0 Acting Deputy Attorney General.Dufresne et Bergeron Compagnie Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the tenth day of April, 1953, incorporating: Joseph Adolphe Dufresne, industrialist, Lorenza Rouleau, housewife, wife separate as to .property of Joseph Adolphe Dufresne, Hubert Bergeron, dealer, and Lucille Lemay, housewife, wife separate as to property of Hubert Bergeron, all of Val d'Or, judicial district of Abitioi, for the following purposes : To carry on the business of grain merchants and to deal in farming implements, and to act as breeders of farm and fur-bearing animals, under the name of \"Dufresne et Bergeron Compagnie Limitée\", with a capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General' this tenth day of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.E.W.Caron & Co.Ltd.E.W.Caron & Cie Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have 1700 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, 23 mai 1953, Tome 85, ;v° 21 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quatorze avril 1953, constituant en corporation: Lucien Roux, avocat, conseil de la Reine.Robert Duhide, avocat stagiaire.Liane Valois, gérante.Lorraine Coté, secrétaire particulière, Hélène St-Denis, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de grains, céréales ou autres produits agricoles de toutes sortes, sous le nom de \"E.W.Caron & Co.Ltd.\" - \"E.W.Caron & Cie Ltée\", avec un capital de 8300,000 divisé en 2.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatorze avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant.34S45-0 C.-E.CANTIN.Farm Désinfection Service Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la premiere partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Riche'ière, conformément à l'article 2, chapitre 270, R.S.Q.,- 1941, des lettres patentes en date du deuxième jour d'avril 1953, constituant en corporation: W.LcM.Owen Carter, avocat, de Sillcry, Harold H.Lindsay, courtier en valeurs.Jean Wallis, secrétaire.Giuliano Spighi, homme d'affaires, Maurice-C.Lanicl, avocat, de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de marchandises effets et articles de toutes sortes connexes aux insecticides, germicides, désifectants, vermicides, fongicides, antiseptiques, sous le nom de \"Farm Désinfection Service Ltd.\", Le capital-actions de la compagnie est divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune et 200 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, ce deuxième jour d'avril 1953.L'Assisbant-procu reu r généra 1, 34845 L.DÉSILETS.Forge Moderne Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de 'a Loi des compagnies de Québec, i' a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du treize avril 1953, constituant en corporation: Marcel Blanchette, Léo-R.Chartrand, tous deux industiiels, de l'Epiphanie,*district judiciaire de Joliette, Fernand-E.Leblanc, comptable-agréé, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Extraire, fondre, transformer les métaux, sous le nom de \"Forge Moderne Inc.\", avec un capital de 840,000, divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à l'Epiphanie, district juoiciaire de Joliette.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourteenth day of April, 1953, incorporating: Lucien Roux, advocate.Queen's Council, Robert Dulude,.Law Student.Liane Valois, manageress, Lorraine Coté, Private Secretary, Hélène St-Denis, secretary all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes:' To deal in grains, cereals or other agricultural * products of all kinds, under the name of \"E.W.Caron & Co.Ltd.\" \u2014 \"E.W.Caron & Cic Ltée\", with a capital stock of 8300,1)00 divided into 2,000 preferred shares of a'par value of $100 each and into 10,000 common shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office ôf the Attorney General the fourteenth dav of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Farm Desinfection Service Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the second day of April, 1953, incorporating: W.LeM.Owen Carter, advocate, of Sillery, Harold H.Lindsay, stock broker, Jean Wallis, secretary, Giuliano Spighi, businessman, Maurice-C.La-niel, advocate, of Quebec, all of the Judicial district of Quebec, for following purposes: To manufacture and deal in goods, wares and merchandise of al kinds connected with insecticides, germicides, disinfectants, vermicides, fungicides, antiseptics, under the name of \"Farm Desinfection Service Ltd.\", The capital stock of the company is divided into 300 preferred shares of the par value of 8100 each, and 200 shares having no nominal or par value; The head office of the Company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General this second dav of April.1953.L.DÉSILETS, 34S45-o Deputy Attorney General.Forge Moderne Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province oi Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelicrc, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of April, 1953, incorporating: Marcel Blanchette, Léo R.Chartrand, both industrialists, of l'Epiphanie, judicial district of Joliette, Fernand E.Leblanc, chartered accountant, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: Extract, melt, transform metals under the name of \"Forge Moderne Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100 each.The' head office of the company will be at L'Epiphanie, judicial district of Joliette. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol.86, No.21 1707 Daté du bureau du Procureur general le treize avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.-E.CANTIN.G.E.Ilamel & Fils Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du dix avril 1953, constituant en corporation: Gcorgës-E.Hamel, fils, marchand, Lucienne Morin, ménagère, épouse contractuel lement séparée de biens du lit Georges-E.Ilamel et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Conrad Brunet, commis, tous de Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'épicerie et de boucherie, sous le nom de \"G.E.Ilamel & Fils Limitée\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 10,000 actions sans valeur au pair ou nominale et 500 actions privilégiées de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jérôme, d'strict judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le dix avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-o C.-E.CANTIN.Georges Painchaud Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.G.La-Richelière.conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941.des lettres patentes, en date du huit avril .1953.constituant en corporation: Réal Marcoux, avocat, de Dorval, Yvon Jasmin, Claude Melançon, avocats.Lucienne Mé-rineau, Rita Dufresne, toutes deux secrétaires, tous quatre de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de marchandises habituellement trafiqués par les \"Ta-baconistes\", confiseurs, marchands généraux, marchands de tissus et de menus articles, sous le nom de \"Georges Painchaud Inc.\", avec un capital de 5200,000 divisé en 20.000 actions communes de $1 chacune et en 1.S00 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le huit avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 3cS'845-o C.-E.CANTIN.Geo.Trudcl, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q.1941.des lettres patentes, en date du neuf avril 1953, constituant en corporation: Georges Trudel, marchand, Lucien Blouin, restaurateur, tous deux de la cité de Québec, et Emilien Blondeau, industriel, de Sillcry, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de mercerie, sous le nom de \"Geo.Trudel, Inc.\".avec un capital de Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of April, 1953.C.-E.CANTIN.34845 Acting Deputy Attorney General.G.E.Ilamel & Fils Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2.chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the tenth day of April 1953, incorporating: Georges-E.Hamel.son, merchant, Lucienne Morin, housewife, wife separate as to property by marriage contract, of the said Georges-E.Ilamel and duly authorized by him for the purposes thereof, Conrad Brunet, e'erk, all of Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To carry on the business of grocer, aim butcher, under the name ot \"G.E.Marne! & Fils Limitée\".The capital stock of the company is divided into 10,000 shares without nominal or par value, and 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, the tenth dav of April 1953.C.-E.CANTIN.34845 Acting Deputy Attorney General.Georges Painchaud Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eight day of April 1953, incorporating: Real Marcoux, advocate, of Dorval, Yvon Jasmin, .Claude Me* lançon, advocates, Lucienne Mérineau, Rita Dufresne, both secretaries, all four of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in merchandise usually dealt in by \"Tobaconists\", confectioners, general merchants, textile materials and smallwa-res' merchants, under the name of \"Georges Painchaud Inc.\".with a capital stock of $200.000 divided into 20,000 common shares of $1 each and 1,800 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General the eighth day of April 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Geo.Trudel, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by thé Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2.chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the ninth day of April, 1953, incorporating: Georges Trudel, merchant, Lucien Blouin, restaurant-keeper, both of the city of Quebec, and Emilien Blondeau, industrialist, of Sillery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of haberdashery, under the name of \"Geo.Trudel.Inc.\", with a ca- 1708 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec» 23 mai 1958, Tome 85, N° 21 §40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le neuf avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34S45-0 L.DÉSILETS.pital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34845 Deputy Attorney General.Ilnnnon Industries Limited \u201e Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnie* de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière.conformément à l'article 2.chapitre 276, S.R.Q.1941.des lettres patentes, en date du neuf avril 1953, constituant en corporation: Georges Hcppell.machiniste, de Longueuil, William-A.Dufour.industriel, de la cité de Montréal, et Thomas-E.Tremblay, agent, de Saint-Vincent-de-Paul, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce connu sous le nom d'atelier de machiniste, sous le nom de \"Hannon Industries Limited\", avec un capital de $50,000, divisé en 500 actions de $100.chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5203, Sicme avenue Rosemont, Montréal, district judiciaire de Montréali Daté du bureau du Procureur général le neuf avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-o C.-E.CANTIN.Hardware Import Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du huit avril 1953, constituant en corporation: Lucien Reed, marchand, Jacques Gougeon, comptable, Elvin Legault, notaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: D'exercer les commerces de marchands en quincaillerie, contraetcurs, constructeurs, plombiers, ferblantiers, couvreurs, sous Je nom de \"Hardware Import Co.Ltd.', avec un capital de $75,000, divisé en 250 actions communes de $100 chacune, et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le huit avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-o C.-E.CANTIN.IL Codcrre & Fils Cie Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière.conformément 4 l'article 2, chapitre 276, R.S.Q.1941, des lettres patentes, en date du seize avril 1953, constituant en corporation: Ovila-J.-B.Goyette, notaire, dr Jean-Paul Provost, dentiste, Thérèse-Renée de Cotrêt, sténodactylo, Gabrielle Ostiguy, secrétaire, tous de Marieville, district judiciajre de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Hannon Industries Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the ninth day of April 1953, incorporating: Georges Heppell, machinist, of Longueuil, William-A.Dufour, industrialist, of the city of Montreal, and Tho, mas-E.Tremblay, agent, of Saint-Yincent-de-Paul, all of the judicial district of Montreal-for the following purposes: To carry on and deal in the business known as a machine shop, under the name of \"Hannon Industries Limited\", with a capital stock of $50,000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at 5203, Eighth Avenue, Rosemont, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the ninth day of April 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Hardware Import Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighth day of April 1953, incorporating: Lucien Reed, merchant, Jacques Gougeon, accountant, Elvin Legault, notary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of hardware merchants, builders, contractors, plumbers, tinsmiths, roofers, under the name of \"Hardware Import Co.Ltd.\", with a capital stock of $75,000, divided into 250 common shares of $100 each, and 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the eighth day of April 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.H.Coderre & Fils Cie Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the sixteenth day of April, 1953, incorporating: Ovila J.B.Goyette, notary, Jean-Paul Provost, dentist, Thérèse-Renée de Cotrêt, sten-typist, Gabrielle Ostiguy, secretary, all of Marieville, judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol.35, No.21 1709 Agir comme marchand de grains, animaux, bois, charbon, huile, matériaux de construction, machineries et instruments agricoles, objets de toutes sortes pour les besoins de la ferme et de la maison; et comme camionneur pour le transport général, sous le nom de \"II.Codcrre & Fils Cie Ltée\", avec un capital de $50,000 divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Knowl-ton, comté de Brome, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général le seize avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant.34815-0 C.-E.CANTIN.Heitner Manufacturing Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Itichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q.1941, des lettres patentes en date du quinzième jour d'avril 1953.constituant en corporation: Morris Shutcr, teneur de livres, Gloria Williams, secrétaire, Conrad Shatner, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de literie, marchandises sèches et articles vestimentaires, sous le nom de \"Heitner Manufacturing Co.Ltd.\" avec un capital de $60,000 divisé en 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quinzième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.-E.CANTIN.Hudon-Robinson Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière.conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941.des lettres patentes en date du quatorzième jour d'avril 1953, constituant en corporation Claude Sartoris Richardson, Conseil en Loi de la Reine, David Henry Holland, avocat, William Patrick Crcagh, étudiant en droit, Cecil Bruce Cooke, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général d'agences et de courtage, sous le nom de \"Hudon-Robinson Ltd.\", avec un capital de $290,000, divisé en 9,600 actions privilégiées d'une valeur au pair de $25«chacune et 500 actions ordinaires dune valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatorzième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.-E.CANTIN.To act as a merchant in grain, livestock, wood, coal oil, building materials, machinery and farming implements, objects of all kinds for farm and home; and as a truck driver for general transportation, under the name of \"H.Codcrre & Fils Cie.Ltée\", with a capital stock of $50,000 divided into 250 common shares of $100 each, and into 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Knowlton, countv of Brome, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney Genera'.Heitner Manufacturing Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière.in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day April, 1953, incorporating: Morris Shuter, bookkeeper, Gloria Williams, secretary, Conrad Shatner, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in sheets, dry goods, and wearing apparel, under the name of \"Heitner Manufacturing Co.Ltd.\", with a capital stock of $60,000.divided into 400 preferred shares having a par value of $100.each, and 200 common shares having a par value of $100.each.- The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifteenth day of April, 1953.C.-E.CANTIN.34845-o Acting Deputy Attorney General.Hudon-Robinson Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent Have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941.bearing date the fourteenth day of April, 1953.incorporating: Claude Sartoris Richardson, Queen's Counsel, David Henry Holland, advocate, William Patrick Creagh, law clerk, Cecil Bruce Cooke, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes': To carry on a general agency and brokerage business, under the name of \"Hudon-Robinson Ltd.\", with a capital stock of 8290,000, divided into 9,600 preferred shares of the par value of $25 each, and 500 common shares of the par value of $100 each.* The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of April.1953.C.-E.CANTIN.34845-0 Acting Deputy Attorney General.Imperial Automotive Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, ;1 a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- Impcrial Automotive Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 1710 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 mai 1958, Tome 85, N° 21 vince do Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément.à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1911, des lettres patentes en date du trente et unième jour de mars 1953.constituant en corporation: Marcus Henry Moscovitch, Saul Corbcr, marchands, Leo Rosentzveig, avocat, de la cité de Montréal, Samuel Leon Mendelsohn, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de la cité do Westmount, tous du district judiciaire do Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes d'automobiles, outillage électrique, ferronnerie, objets divers d'optique, effets de ménage, sous le nom de \"Imperial Automotive Co.\", avec un capital de §200,000, divisé en 1,500 actions privilégiées et 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce trente et unième jour do mars 1953.L'Assistant-procureur général.34845 L.DÉSILETS.Jean Avard Inc.Avis est.donné qu'en ver|u do la première partie de la Loi dos compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière.conformément à l'article 2, chapitre 276.S.R.Q.1941, des lettres patentes, on date du dix .avril 1953.constituant en corporation: Alfred Tourigny, avocat, d'Outremont, Rita Dufresne, Lucienne Mérineau.filles majeures, secrétaires, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme courtiers en assurances et agents ?d'assurances, sous le nom de \"Jean Avard Inc.\", avec un capital de §50,000 divisé en 1,000 actions communes de §10 chacune, et en 4,000 actions privilégiées de §10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34S45-o C.-E.CANTIN.Joseph L.Abel Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 2(6, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix avril 1953, constituant en corporation : Joseph-Lorenzo Abel, Paul Abel, fabricants de coca-cola, de Saint-Joseph d'Alma, et Dame Marthe Abel Delisle, ménagère, de ITsle-Maligne, tous du district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Acquérir des recettes, formules ou autres informations pour la fabrication, la préparation, l'embouteillage et le commerce d'eaux gazeuses et de toutes autres préparations chimiques, sous le nom de \"Joseph L.Abel Limitée\", avec un capital de §40,000 divisé on 4,000 actions de §10 chacune.Le siège social de la compagnie sera situé à Route Saint-Bruno, Saint-Joscph-d'Alma, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général le dix avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.-E.CANTIN.Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2.chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the thirty-first day of March, 1953, incorporating: Marcus Henry Moscovitch.Saul Corber.merchants, Leo Rosentzveig, advocate, of the city of Montreal, Samuel Leon Mendelsohn, advocate and Queen's Counsel, of the city of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of automobiles, electrical equipment, hardware, optical sundries, household wares, under the name of \"Imperial Automotive Co.\".with a capital stock of $200,000.divided into 1,500 preferred shares and 500 common shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at N Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first dav of March.1953.L.DÉSILETS, 34845-0 Deputy Attorney General.Jean Avard Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.' C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276,-R.S.Q.1941, bearing date the tenth day of April 1953, incorporating: Alfred Tourigney, advocate, of Outremont, Rita Dufresne, Lucienne Mérineau, spinsters, secretaries, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as insurance brokers and agents, under the name of \"Jean Avard Inc.\", wich a capital stock of $50,000 divided into 1,000 common shares of $10 each, and 4,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the tenth dav of April 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Joseph L.Abel Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière.in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q.1941, bearing date the tenth day of of April, 1953, incorporating: Joseph-Lorenzo Abel, Paul Abel, manufacturers of Coca-cola, of Saint-Joseph d'Alma, and Dame Marthe Abel Delisle.housewife, of Isle-Maligne, all of the judicial district of Roberval, for the following purposes: Acquire recipes, formulas or other information for the manufacture, preparation, bottling and the dealing in gaseous waters and all other chemical preparations, under the name of \"Joseph L.Abel Limitée\", with a capital stock of §40,000 divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be situate at Route Saint-Bruno, Saint-Joseph-d'Alma, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, the ten day of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol.85, No.21 1711 La Briqueterie Mistassini, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de-la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.('.Laliiche-lièrc, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 19-H, des lettres patentes.cn date du 9 avril 1953, constituant en corporation: Charles-Edouard Perron, industriel, Elzéar Savard, cultivateur, Georges Villeneuve, notaire, tous de Mistassini, district judiciaire de Roberval, poulies objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de la brique, du terra-cota, du tuyau de grès, du tuyau de béton, sous le nom :1e \"La Briqueterie Mistassini, Inc.\", avec un capital de $100.000.divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mistassini, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général le neuf avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34845 L.DÉSILETS.La Chamhrcttc Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.('.LaRiche-lièrc, conformément à l'article 2, chapitre 270.S.R.Q., 1941.des lettres patentes, en date du onze avril 1953, constituant en corporation: Jean-Noël Lavoie, notaire, de PAbord-à-Plouffe, Maur rice Lavoie, contracteur, René Saint-Jean, commerçant, tous deux de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer en général le commerce d'hôtellerie, sous le nom de \"La Chambrette Limitée\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Martin, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le onze avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-o _ C.-E.CANTIN.La Cie Jarry-Fabrc Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du premier jour d'avril 1953, constituant en corporation: Clarence Francis McCaffrey, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Donald Powell Wilson, auteur, Hugh Rafferty, constructeur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux dans la construction et l'outillage de travaux publics et privés, sous le nom de \"La Cie Jarry-Fabre Ltée\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce premier jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur généial, 34845 L.DÉSILETS.La Briqueterie Mistassini, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2.chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the ninth day of April, 1953, incorporating: Charles-Edouard Perron, industrialist, Elzéar Savard.farmer, Georges Villeneuve, notary, all cf Mistassini.judicial district of Roberval, for the following purposes: .To carry on the business and trade in brick, terra-cota, clay pipes, concrete pipes, under the name of \"La Briqueterie Mistassini, Inc.\", with a capital stock of $100,000.divided into 1.000 shares of S100 each.The head office of the company will be at Mistassini, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of April, 1953.L.DÉSILETS, 34845 Deputy Attorney General.La Chambrette Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'.Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eleventh day April, 1953, incorporating.* Jean-Noël Lavoie, notary, of Abôrd-à-Plouffe, Maurice Lavoie, contractor, René Saint-Jean, dealer, both of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal generally in the hotel business, under the name of \"La Chambrette Limitée\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Saint-Martin, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.La Cie Jarry-Fahre Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276.R.S.Q.1941, bearing date the first day of April, 1953, incorporating: Clarence Francis McCaffrey, Barrister and Queen's Counsel, Donald Powell Wilson, Author.Hugh Rafferty, builder, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors for the construction and equipment of public and private works, under the name of \"La Cie Jarry-Fabre Ltée\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of 8100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this first dav of April, 1953.L.DÉSILETS, 34845-0 Deputy Attorney General. / La Companic de Publication \"L'Économie Rurale\" Inc\\ Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date^ du sept avril 1953, constituant en corporation: Roger Bernard, Jean-Marie Boulanger, publicis-tes, et Rita Lebrun, ménagère, épouse séparée de biens de Roger Bernard, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter l'industrie de l'imprimerie et de la publicité, sous le nom de \"La Compagnie de Publication \"L'Économie Rurale\" Inc.\", avec un capital de §40,000 divisé en 3,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté'du bureau du Procureur général le sept avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.-E.CANTIN.La Ligue des Propriétaires de St-Simon de Drummond Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du treize avril 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Théo Logier, marchand, Alfred Morissette, rentier, Odilon St-Louis, Raymond Couture, employés d'usine, tous de Saint-Simon-de-Drummond, district judiciaire d'Arlhabaska, pour les objets suivants: L'étude de la défense des intérêts des propriétaires, sous le nom de \"La Ligue des Propriétaires de Saint-Simon ,1e Drummond\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $10,000.Le siège social de la corporation sera fl Saint-Simon-de-Drummond, district judiciaire d'Ar-thabaska.Daté du bureau du Procureur général le treize avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.-E.CANTIN.La Companic de Publication \"L'Economie Rurale\" Inc.Notice is hereby given that under Part I of.the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, ii) conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of April 1953, incorporating: Roger Bernard, Jean-Marie Boulanger, publicists, and Rita Lebrun, housewife, wife separate as to property of Roger Bernard, all three of the city and judicial district or Montreal, for the following purposes: To carry on a printing and publicity business, under the name of \"La Compagnie de Publication \"L'Économie Rurale\" Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 3,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, April seventh 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.La Ligue des Propriétaires de Si -Simon de Drummond Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2\u201e chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of April, 1953, to incorporate as a corporation without capital stock: Théo Logier, merchant, Alfred Morissette, rentier, Odilon St-Louis, Raymond Couture, factory employees, all of Saint-Simon-de-Drummond, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: The study of the defence of the interests of property owners, under the name of \"La Ligue desPropriétaircsdeSaint-Simon de Drummond.\" The amount to which the value of immoveable property which the corporation may hold is to to be limited is, $10,000.The head office of the corporation will be £t Saint-Simon-de-Drummond, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, the thirteenth dav of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Leanora DcRice Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du sentième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Benjamin Robinson, avocat et Conseil en Loi de la Reine; de Westmount, Theodore H.Shapiro, avocat, de Ville Mont-Royal, Ethel Yussem, secrétaire, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: \u2022 Exercer le commerce d'un restaurant, sous le nom de \"Leanora DeRice Inc:\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.» Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Leanora DeRice Inc.Notice is htfreby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieuteuant-Governor of the Province of Quebec, representee! by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2.chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of April, 1953, incorporating: Benjamin Robinson, advocate and Queens' Counsel, of Westmount, Theodore H.Shapiro, advocate, of the Town of Mount Royal, Ethel Yussem, secretary, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a restaurant, under the name of \"Leanora DeRice Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.V 1712 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 mai 1958, Tome 85, N° 21 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol.85, So.21 1713 Daté du bureau du Procureur général, ce Dated at the office of the Attorney General, septième jour d'avril 1953.this seventh day of April.1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 34845 L.DÉSILETS.34845-o Deputy Attorney General.Les Clubs Juvéniles de la Cité v de Jacques-Cartier Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément a l'article 2.chapitre 276.S.R.Q.1941.des lettres patentes, en date du seize avril 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Ovila-J.B.Goyette, notaire, Jean-Louis Mayer, médecin, Jean-Paul Provost, dentiste, A.-Maurice Bouchard, gérant, Roland Boulais, menuisier, Guy Rondeau, agent, Louis-Philippe Rondeau, étudiant, Michelle-Andrée Monast, garde-malade licenciée, Thérèse-Renée de Cotrêt, sténo-dactylo, Rita Poulin, secrétaire, Gabrielle Ostiguy, Thérèse Tawel, commis, M.l'abbé Georges-Henri Cournoyer, prêtre-vicaire, tous de Marieville, district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Agir comme centre social et récréatif et organiser les loisirs de la jeunesse afin de prévenir la délinquence juvénile, sous le nom de \"Les Clubs Juvéniles de la Cité de Jacques-Cartier Inc.\" Le siège social de la corporation sera à Ville Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le seize avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.-E.CANTIN.I«> Clubs Juvéniles de la Cité de Jacqucs-Curticr Inc.Notice is hereby given that under Part IILof the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941.bearing date the sixteenth day of April.1953.to incorporate as a corporation without capital stock: Ovila J.B.Goyette, notary, Jean-Louis Mayer, physician, Jean-Paul Provost, dentist, A.Maurice Bouchard, manager, Roland Boulais, joiner, Guy Rondeau, agent, Louis-Philippe Rondeau, student, Michelle-An-drée Monast, registered nurse, Thérèse-Renée de Cotrêt, sten-typist, Rita Poulin, secretary, Gabrielle Ostiguy, Thérèse Tawel, clerks, Father Georges-Henri Cournoyer, parish priest, all of Marieville, judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To act as a social and recreative centre and organize young people's leasure time in order to prevent juvenile delinquency, under the name of \"Les Clubs Juvéniles de la Cité de Jacques-Cartier Inc.\".The head office of the corporation will be at Ville Jacques-Cartier, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the sixteenth day of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.l.illimar Scarves Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies tie Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q., 1941, des lettres patentes en date du neuvième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Marcus Perlman, manufacturier, Lillian Averson, épouse st'parée de biens de Joel Marcovitz, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Lazarus L.Tinkoff, Arthur Levin, tous deux avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de foulards, cravates, coiffures, accessoires de robes, gants et mitaines, fleurs artificielles, et aussi celui d'imprimer à la trame, sous le nom de \"Lillimar Scarves Inc.\", avec un capital de 8100,000 divisé en 2,400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 7600 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune., Le siège social de la compagnie sera à 6750 rue.Hutcliison, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce neuvième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.-E.CANTIN.Lillimar Scarves Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the ninth day of of April, 1953, incorporating: Marcus Perlman, manufacturer, Lillian Averson, wife separate as to property of Joel Marcovitz, and duly authorized by him for the purposes of these presents, Lazarus L.Tinkoff, Arthur Levin, both advocates, all of the city and judicial district of Montreal for the following purposes: To manufacture and deal in scarves, neckwear, dress accessories, gloves and mitts, artificial flowers, screen printing, under the name of \"Lillimar Scarves Inc.\", with a capital stock of $100,000.divided into 2,400 common shares of a par value of $10.each and 7600 preferred shares of a par value of $10.each.The head office of the Company will be at 6750 Hutchison Street.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this ninth dav of April.1953.C.-E.CANTIN, 34845-o Acting Deputy Attorney General.L'Irrigation Moderne Inc.L'Irrigation Moderne Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été the Quebec Companies' Act, letters patent have accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- been issued by the Lieutenant-Governor of the rince de Québec, représenté par M.C.LaRiche- Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi- 1714 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 mai 1053.Tome 86, N° 21 Hère, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du treize avril 1953, constituant en corporation: .lean Tcllier, courtier en assurances, Pierre Tellier, commis de bureau, Pierre-Paul Beau-douin, vendeur-gérant, tous de Joliette, district judiciaire de Joliette, pour les objets suivants: Manufacturer de la tuyauterie, des pompes, des joints, et tous autres articles nécessaires a l'installation de systèmes d'irrigation et en faire commerce, sous le nom de \"L'Irrigation Moderne Inc.\", avec un capital de $10,000 divisé en 1,000 actions de $10 chacune'.Le siège social de la compagnie sera à 416, rue Manseau, Joliette, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général le treize avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.-E.CANTIN.L'Oeuvre des Terrains de Jeux et des Loisirs Jacques Cartier, Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q., 19-11, des lettres patentes, en date du treize avril 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Alfred Plante, électricien, Joseph St-Amand, menuisier.Franc's Assclin, marchand, tous de Ville Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Organiser les loisirs de la population et principalement des enfants de Jacques-Cartier, sous le nom de \"L'Oeuvre des Terrains de Jeux et des Loisirs Jacques-Cartier, Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $40,000.Le siège social de la corporation sera à Ville Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le treize avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.-E.CANTIN.Lou Spier Inc.Avis est'donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compaguies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du neuvième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Clarence Reuben Gross, avocat, Evelyn Shane, secretaire, et Sarah Miller, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements, articles vestimentaires, fourrures, marchandises sèches et fournitures, sous le nom de \"Lou Spier Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce neuvième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, \u2022 34845 L.DÉSILETS.chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941.bearing date the thirteenth day of April, 1953, incorporating: Jean Tellier, incurance broker, Pierre Tellier, office clerk, Pierre-Paul Beaudoin, sales manager, all of Joliette,-judicial district of Joliette, for the following purposes: \u2022 To manufacture pipes, pumps, joints and all other articles necessary for the installation of irrigation systems ami to trade therein, under the name of \"L'Irrigation Moderne Inc.\".with a capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 410, Manseau Street, Joliette, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of April.1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.L'Oeuvre des Terrains de Jeux et des Loisirs Jacques Cartier, Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of April 1953, to incorporate as a corporation without capital stock: Alfred Plante, electrician, Joseph St-Amand, carpenter, Francis Assclin.merchant, all of the town .of Jacques-Cartier, judicial district of Montreal, for the following purposes: To organize recreation for the population and more especially for the children of Jacques Cartier, -under the name of \"L'Oeuvre des Terrains de Jeux et des Loisirs Jacques-Cartier, Inc.\".The amount to which the value of immoveable property which the corporation may bold is to be limited, is $40,000.The head office of the corporation will be in the Town of Jacques-Cartier, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the thirteenth day of April 1053.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Lou Spier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, représente* 1 by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the ninth day of April, 1953, incorporating: Clarence Reuben Gross, advocate, Evelyn Shane, secretary, and Sarah Miller, stenographer, all of the city and Judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing, wearing apparel, furs, dry goods and furnishings,under the name of \"Lou Spier Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 300 preferred shares of the par value of $100.each, and 100 common shares of the par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this ninth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34845-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol 85, No.21 1715 Manik Construction Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du du treize avril 1953, constituant en corporation: Gilles Rouleau, avocat, Maurice Carpentier, comptable, Bérangère Vignolas, secrétaire, tous de Baie Comeau, district judiciaire de Saguenay, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Manik Construction Company Limited\", avec un capital de $75,000 divisé en 500 actions communes de $100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Baie Comeau, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général le treize avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.-E.CANTIN.Marché A.& B.Market Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du huitième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Ben Udashkin, marchand, Lily Ahra-mowitz, épouse commune en biens dudit Ben Udashkin, Gérald Udashkin, marchand, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce de bouchers et épiciers, sous le nom de \"Marché A.& B.Market Limited\" avec un capital de $50,000, divisé en 300 actions privilégiées de $100 chacune et 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce huitième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34845 L.DÉSILETS.Mintz Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.CLaRichc-'ière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dixième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Lawrence Mintz, administrateur, de Détroit, État de Michigan, un des États-Unis d'Amérique, June Kirlin secrétaire, Blanka Gyulai, teneuse de livres, veuve, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et faire le commerce d'immeubles ou intérêts et propriétés immobilières, sous le nom de \"Mintz Holdings Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune, et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.-E.CANTIN.Manik Construction Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of April 1953, incorporating: Gilles Rouleau, advocate, Maurice Carpentier, accountant, Bérangère Vignolas, secretary, all of Baie Comeau, judicial district of Saguenay, for the following purposes: To carry on business as general contractors, under the name of \"Manik Construction Company Limited\", with a capital stock of $75,000 divided into 500 common shares of $10 each, and 250; preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Baie Comeau, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, the thirteenth day of April 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Marché A.& B.Market Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighth day of April, 1953, incorporating: Ben Udashkin, merchant, Lily Abramowitz, wife common as to property of the said Ben Udashkin, Gerald Udashkin, merchant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of butchers and grocers, under the name of \"Marché A.& B.Market Limited\", with a capital stock of $50,000.divided into 300 preferred shares of $100 each, and 200 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34845-0 Deputy Attorney General.Mintz Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the tenth day of April, 1953, incorporating: Lawrence Mintz, executive, of Detroit, State of Michigan, one of the United States of America, June Kirlin, secretary, Blanka Gyulai, bookkeeper, widow, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with real estate or interests and immoveable property, under the name of \"Mintz Holdings Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 300 preferred shares having a par value of $100 each, and 100 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845-u Acting Deputy Attorney General. 1716 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 mai 1953, Tome 85, N° 21 Mont Gabriel Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q., 1941, des lettres patentes en date du trente et unième jour de mars 1953, constituant en corporation: Roy Fraser Ëlliott, avocat, Mary Bergin, Lillian Viola Armstrong, Mary Elizabeth Spracklin et Margot Mary Quinn, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir, faire le commerce et le négoce de terrains et immeubles, sous le nom de \"Mont Gabriel Realties Ltd.\", avec un capital de $5,000 divisé en 5,000 actions d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 606 rue Cathcart, en les cité et district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce trente et unième jour de mars 1953.L'Assistant-procurcur gênéral, 34845 L.DÉSILETS.Mont Gabriel Realties Ltd.Notice is hereby given that under .Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity-with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirty-first day of March, 1953, incorporating: Roy Fraser Elliott, advocate, Mary Bergin, Lillian Viola Armstrong, Mary Elisabeth Spracklin, and Mar-got Mary Quinn, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with lands and real estate, under the name of \"Mont Gabriel Realties Ltd.\", with a capital stock of 85,000.divided into 5,000 shares of the par value of 81.each.The head office of the Company will be at 000 Cathcart Street, in the city ami judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirty-first dav of March, 1953.L.DÉSILETS, 34845-0 Deputy Attorney General.M.Provost Automobiles Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Hé accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q.1941, des lettres patentes, en date du treize avril 1953, constituant en corporation: Jean Mottet, industriel, de la cité d'Outrcmont, Maurice Provost, et Lionel Provost, vendeurs, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Maintenir, gérer et opérer des garages, sous le nom de \"M.Provost Automobiles Limitée\", avec un capital de 875,000 divisé en 750 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le treize avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.-E.CANTIN.Peel Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dixième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Henri-Paul Lemay, Bernard Lebel, avocats, de la cité de Montréal, Paul-Edouard Ross, avocat, de Verdun, et Ghislaine Gagné, secrétaire, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de placements et de courtage, sous le nom de \"Peel Investment Corporation\", avec un capital de $100,000, divisé en 990 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.-E.CANTIN.M.Provost Automobiles Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 270, R.&Q.1941, bearing date the thirteenth day of April 1953, incorporating: Jean Mottet, industrialist, of the city of Outremont, Maurice Provost, and Lionel Provost, salesmen, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To maintain, manage and operate garages, under the name of \"M.Provost Automobiles Limitée\", with a capital stock of $75,000 divided into 750 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the thirteenth dav of April 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Peel Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the tenth day of April, 1953, incorporating: Henri-Paul Lemay, Bernard LcBel, advocates, of the city of Montreal, Paul-Edouard Ross, advocate, of Verdun, and Ghislaine Gagné, secretary, of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a general investment and brokerage business, under the name of \"Peel Investment Corporation\", with a capital stock of $100,000, divided into 990 preferred shares of the par value of $100 each, and 1,000 common shares of the par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845-Q Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol 85, No.21 1717 Placage Industriel, Inc.Industrial Electroplating, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du quatorze avril 1953, constituant en corporation: Henry Lessard, Paul Gelly, commis, L.-Eugène ('antin, importateur, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce, le métier et la profession d'orfèvres et bijoutiers, sous le nom de \"Placage Industriel, Inc.\" \u2014 \"Industrial Electroplating, Inc.\", avec un capital de 840,000 divisé en 1,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et en 2,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 687, Ouest, rue Saint-Vallier, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le quatorze avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34845-0 L.DÉSILETS.Placage Industriel, Inc.Industrial Electroplating, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourteenth day of April 1953, incorporating: Henry Lessard, Paul Gelly, clerk, L.-Eugène Cantin, importer, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business, trade and profession of goldsmiths and jewellers, under the name of \"Placage Industriel, Inc.\" \u2014 \"Industrial Electroplating, Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 1,500 common shares of a par value of $10 each, and 2,500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 687, St-Valicr Street, West, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, the fourteenth day of April 1953.C.-E.CANTIN.34845 Acting Deputy Attorney General.Produits Diamant, Products Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q.1941, des lettres patentes, en date du quatorze avril 1953, constituant en corporation: Joseph Vachon, Amédée Vachon, Benoit Va-chon, Paul Vachon, industriels, tous de Sainte-Marie, district judiciaire de Beauce, pour les objets suivants: Manufacturer, faire le commerce, empaqueter, mettre en conserve, les produits alimentaires, sous le nom de \"Produits Diamant, Products Inc.\", avec un capital de $100,000 divisé en 240 actions ordinaires de $100 chacune et en 760 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Marie, district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du Procureur général le quatorze avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.-E.CANTIN.Provincial Acceptance Corporation Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie dé la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q.1941, des lettres patentes, en date du huit avril 1953, constituant en corporation: Wilfrid Page, président de Page & Fils Limitée, Maurice Limoges, gérant général, Gérard Jo-doin, gérant d'affaires, Paul-Henri Chenette, secrétaire-trésorier et comptable, tous de Verdun, Jacques Vézina, comptable, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme agent financier et préteur d'argent, sous le nom de \"Provincial Acceptance Corporation Limited\", avec un capital de $460,000 divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 4,500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Verdun, district judiciaire de Montréal.Produits Diamant, Products Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourteenth day of April, 1953, incorporating: Joseph Vachon, Amédée Vachon, Benoit Vachon, Paul Vachon, industrialists, all of Sainte-Marie, judicial district of Beauce, for the following purposes: To manufacture, deal in, pack, can food products under the name of \"Produits Diamant, Products Inc.\", with a capital stock of $100,000 divided into 240 common shares of $100 each and into 760 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saintc-Marie, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General the fourteenth day of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Provincial Acceptance Corporation Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the eighth day of April, 1953, incorporating: Wilfrid Page, president of Page & Fils Limitée, Maurice Limoges, general manager, Gérard Jodoin, business manager, Paul-Henri Chencttc, secretary-treasurer and accountant, all of Verdun, Jacques Vézina, accountant, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as financial agent and money lender, under the name of \"Provincial Acceptance Corporation Limited\", with a capital stock of $460,000 divided into 10,000 common shares of $1 each and into 4,500 preferred shares or $100 each.The head office of the company will be at Verdun, judicial district of Montreal. 1718 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S3 mai 1953, Tome 85, N° SI Daté du bureau du Procureur général le huit avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 3845-c.C.-E.CANTIN.Provost Fruit Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du septième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Joe Wexler, Armand Provost, marchands, Sybil Marter, secrétaire, épouse séparée de biens de Frank Martel, Mary Goldwater, secrétaire, épouse séparée de biens de Sydney L.Goldwater, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchands en produits alimentaires, viandes, poissons, produits laitiers, céréales et tous produits agricoles et naturels sous le nom de \"Provost Fruit Co.\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34845 L.DÉSILETS.Rapid Construction Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du treize avril 1953, constituant en corporation: Henri-Paul Abbott, ingénieur.Benoît Côté, professeur, tous deux des Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières, et Gilles Beausé-jour, assureur, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Opérer le commerce de la construction, sous le nom de \"Rapid Construction Ltée\", avec un capital de $30,000, divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera aux Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le treize avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-o C.-E.CANTIN.Restaurant Bonnet Bleu Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du septième jour d'avril 1953, constituant en corporation : Benjamin Robinson, Conseil en Loi tie la Reine, de la cité tie Westmount, Theodore H.Shapiro, de Ville Mont-Royal, tous deux avocats, et Ethel Yussem, secrétaire, fille majeure, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire ce Montréal, pour les objets suivants: Dated at the office of the Attorney Genera' this eight day of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Provost Fruit Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day Arpil, 1953, incorporating: Joe Wexler, Amand Provost, merchants, Sybil Marter, secretary, \u2022wife separate as to property from Frank Marter, Mary Goldwater, secretary, wife separate as to property from Sydney L.Goldwater, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dealers in foodstuffs, meat, fish, dairy and all other cereal, agricultural and natural products, under the name of \"Provost Fruit Co.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of the par value of $100 each and 200 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34845-0, Deputy Attorney General.Rapid Construction Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of April 1953, incorporating: Henri-Paul Abbott, engineer, Benoit Côté, professor, both of Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières, and Gilles Beauséjour, insurance agent, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate a construction business, under the name of \"Rapid Construction Ltée\", with a capital stock of $30,000, divided into 150 common shares of $100 each and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, the thirteenth day of April 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Restaurant Bonnet Bleu Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the^ Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventh day of April, 1953, incorporating: Benjamin Robinson, Queen's Counsel, of the City of Westmount, Theodore H.Shapiro, of the Town of Mount Royal, both advocates, and Ethel Yussem, secretary, of the full age of majority, of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1958, Vol.85, No.21 1719 Exercer le commerce d'un restaurant, sous le nom de \"Restaurant Bonnet Bleu Ltée\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.-E.CANTIN.Rhéaume & Rhéaume Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix avril 1953, constituant en corporation: Lorenzo Rhéaume, entrepreneur forestier, de Lac Saint-Charles, Lucien Rhéaume, entrepreneur forestier, de Notre-Dame des Laurentides, Roger Jobidon, enquêteur, de Château-d'Eau, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants : Bois de construction et opérations forestières; et exploiter le commerce de contracteur général et de constructeur, sous le nom de \"Rhéaume & Rhéaume Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lac St-Charles, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le dix avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34845-o L.DÉSILETS.Riverside-Chibougama Mines Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du septième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Juliette Lapierre, Isabelle Lemay,.sténographe, Bernade Charette, comptable, de Montréal, Rose-Aimée Poudrette, sténographe, de Boucherville, Hélène Monette, sténographe, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Riverside-Chibougama Mines Limited\" (Libre de responsabilité personnelle) avec un capital de $3,000,000 divisé en 3,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34845 L.DÉSILETS.Robert Construction Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- To carry on the business of a restaurant, under the name of \"Restaurant Bonnet Bleu Ltée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventh day of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845-0 Acting Deputy Attorney General.Rhéaume & Rhéaume Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the tenth day of April 1953, incorporating: Lorenzo Rhéaume, timber contractor, of Lake St.Charles, Lucien Rhéaume, timber contractor, of Notre-Dame-des-Laurentides, Roger Jobidon, investigator, of Chateau-d'Eau, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in wood suitable for construction and carry out forestry operations; to carry on the business of general contractor and builder, under the name of \"Rhéaume & Rhéaume Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Lake St.Charles, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, the tenth day of April 1953.L.DÉSILETS, 34845 Deputy Attorney General.Riverside-Chibougama Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of April, 1953, incorporating: Juliette Lapierre, Isabelle Lemay, stenographer, Bernade Charette, accountant, of Montreal, Rose-Aimée Poudrette, stenographer, of Boucherville, Hélène Monette, stenographer, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Riverside-Chibougama Mines Limited\" (No Personal Liability), with a capital stock of $3,000,000, divided into 3,000,000 shares of $1 each.The shareholders shall incur no personal liability in excess of the amount paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1953.L.DÉSILETS.34845-o Deputy Attorney General.Robert Construction Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent hvae been issued by the Lieutenant-Governor of the 1720 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S3 mai 1953, Tome 86, N° SI vince de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du neuf avril 1953, constituant en corporation: Léo-Paul Robert, industriel, Marcel Morin, notaire, Marcel Rivard, comptable, tous de Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Robert Construction Limitée\", avec un capital de 840,000, divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général le neuf avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.-E.CANTIN.Show-Mart Parking Inc.Stationnement du Palais du Commerce Inc Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q.1941, des lettres patentes en date du quinze avril 1953, constituant en corporation : Paul Cloutier, homme d'affaires, Harry Blank, avocat, June Kirlin, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Posséder, entretenir, exploiter et administrer des garages, entrepôts et terrains de stationnement, sous le nom de \"Show-Mart Parking Inc.\" \u2014 \"Stationnement du Palais du Commerce Inc.\", avec un capital de 840,000 divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.-E.CANTIN.South Shore Tank Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur cie la province de Québec, représenté par M.C.La-Riche'ière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-septième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Bernard Desjarlais, avocat, de Verdun, Albert Ouellettc, avocat, de Ville Lasal-le, Roma Cousincau, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme fondeurs de fer et bronze, fabricants d'outils, travailleurs de métaux, fabricants de bouilloires, constructeurs de machineries de moulins, monteurs de structures en fer et acier, connecteurs, forgerons, travailleurs de bois, soudeurs, constructeurs, métallurgistes et transporteurs, sous le nom de \"South Shore Tank Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-septième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.-E.CANTIN.Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the ninth day of April 1953, incorporating: Léo-Paul Robert, industrialist, Marcel Morin, notary, Marcel Rivard, accountant, all of Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Robert Construction Limitée\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, the ninth day of April 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Show-Mart Parking Inc.Stationnement du Palais du Commerce Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day of April, 1953, incorporating: Paul Cloutier, businessman, Harry Blank, advocate, June Kirlin, secretary, a'l of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To keep, maintain, operate and manage garages, warehouses, parking lots, under the name of \"Show-Mart Parking Inc.\" \u2014 \"Stationnement du Palais du Commerce Inc.\", with a capital stock of 840,000.divided into 300 preferred shares having a par value of $100.each, and 100 common shares having a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifteenth day of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845-0 Acting Deputy Attorney General.South Shore Tank Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q.1941, bearing date the seventeenth-day of April, 1953, incorporating: Bernard Desjarlais, advocate, of Verdun, Albert Ouellette, advocate, of Ville Lasalle, Roma Cousineau, advocate, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of iron and brass founders, tool makers, metal workers, boiler makers, millwrights machinists, iron and steel erectors, connecters, smiths, woodworkers, welders, builders, metallurgists and carriers, under the name of \"South Shore Tank Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Ville Jacques-Cartier, in the judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventeenth day of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845-0 Acting Deputy Attorney Genera. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol.85, No.21 1721 Syndicat Commercial Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du neuf avril 1953, constituant en corporation: François Morel, avocat, Florence Lehoux, Rita Savaria, sténographes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises dans la fabrication «lesquels entrent du cuir, du caoutchouc, du métal, du bois, du papier, du nylon, du platique, de la fourrure, des textiles, du verre, ainsi que de leurs sous-produits, sous le nom de \"Syndicat Commercial Ltée\", avec un capital de $110,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le neuf avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845-0 C.-E.CANTIN.Syndicat Commercial Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelièrc, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the ninth day of April 1953, incorporating: François Morel-advocate, Florence Lehoux, Rita Savaria, sténo, graphers, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all sorts of products, articles, and merchandise, in the manufacturing of which leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textile, glass, as well as their by-products are used, under the name of \"Syndicat Commercial Ltée\", with a capital stock of 8110,000 divided into 1,000 common shares of 810 each and 1,000 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the ninth day of April 1953.C.-E.CANTIN, 34845 Acting Deputy Attorney General.Universal Ship Supply Ltd.Avis est donné qujen vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du septième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Maxwell Alter Schwartz, avocat, Irving Morton, comptable, de Montréal, Irwin B.Cohen, avocat, de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce et le négoce de tous accessoires ordinairement vendus par les fournisseurs de navires et tous autres produits de ferronnerie, sous le nom de \"Universal Ship Supply Ltd.\", avec un capital de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34845 C.-E.CANTIN.Universal Ship Supply Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière.in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of April, 1953, incorporating: Maxwell Alter Schwartz, advocate, Irving Morton, accountant, of Montreal, Irwin B.Cohen, advocate, of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal with or in all supplies customarily dealt with by ship chandlers, and all other hardware products, under the name of \"Universal Ship Supply Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh dav of April, 1953.C.-E.CANTIN, 34845-0 Acting Deputy Attorney General.Windsor Mine Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 276, 1941, des lettres patentes, en date du neuf avril 1953, constituant en corporation: Alfred Nadeau, hôtelier, Raphaël Laccrte, cultivateur, Hortence Lacertc, ménagère, tous d'Asbestos, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Faire l'exploitation de carrières, mines, minerais et de tous leurs sous-produits, sous le nom de \"Windsor Mine Corporation\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune Le siège social de la compagnie sera à 245, Saint-Jean-Baptiste, Asbestos, district judiciaire de Saint-François.Windsor Miné Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the ninth day of April 1953, incorporating: Alfred Nadeau, hotel-keeper, Raphaël Lacerte, farmer, Hortence Laccrte, housewife, all of Asbestos, judicial district of Saint Francis,for the following purposes: To carry out the development of quarries, mines, ores and by-products thereof, under the name of \"Windsor Mine Corporation\", with a capital stock of 840,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 245 Saint-Jean-Baptiste, Asbestos, judicial district of Saint-Francis. 1722 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S3 mai 1953, Tome 85, N° 21 Daté du bureau du Procureur général le neuf Dated at the office of the Attorney General, avril 1952.the ninth day of April 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 34845-o L.DÉSILETS.34845 Deputy Attorney General.Jos.Morneau Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la 5>rovince de Québec, représenté par M.C.La-tichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 27G, des lettres patentes, en date du premier avril 1953, autorisant la fusion des compagnies \"Jos Morneau Inc.\", constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 24 janvier 1936, et \"Morneau Limitée\", constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 25 juillet 1944, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce du bois, et faire le commerce de valeurs et placements, sous le nom de \"Jos.Morneau Inc.\", avec un capital total de $150,000, divisé en 10,000 actions privilégiées de $10 chacune et en 500 actions ordinaires de $100 chacune.Le nom de la nouvelle compagnie est \"Jos.Morneau Inc.\" Le bureau principal de la compagnie sera au numéro 150, 10e rue est, dans la ville de Char-lesbourg, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le 1er avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34845-0 L.DÉSILETS.Jos.Morneau Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with Section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, bearing date the first day of April 1953, authorizing the a-malgamation of \"Jos.Morneau Inc.\", a company incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act by letters patent dated January 24, 1936, and \"Morneau Limitée\", a company incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act by letters patent dated July 25, 1944, for the following purposes: To carry on and deal in the lumber business, and to trade in securities and investments, under the name of \"Jos Morneau Inc.\", with a total capital stock of $150,000, divided into 10,000 preferred shares of $10 each, and 500 common shares of $100 each.The name of the new Company is \"Jos Morneau Inc.\" The head office of the Company shall be at number 150, 10th Street, East, in the town of Charlesbourg, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, the first day of April 1953.L.DÉSILETS, 34845 Deputy Attorney General.Actions en séparation de biens Canada, Province de Québe\\ District de Montréal, Cour Supérieure, N° 332347.Dame Harmina Boisjoly, demanderesse, vs J.Duhamel, défendeur.AVIS Dame Hermina Boisjoly, épouse de J.Duhamel, domicilié à Montréal, a formé- contre son mari une demande en séparation «le biens.Montréal, le 30 avril 1953.Vraie copie.Le Procureur de la demanderesse.34847-o M.G.VADEBONCOEUR.Province de Québec, District de Montréal, Cour Supérieure, N° 332996.Dame Gertrude Paradis, demanderesse, vs Edgar Milot, défendeur.Dame Gertrude Paradis, des cité et district de Montréal, épouse commune en biens de Edgar Milot, entrepreneur-peintre, du même lieu, a intenté une action en séparation de biens contre son mari.Montréal, 14 mai 1953.Actions for separation as to property Canada, Province of Quebec, District of Montreal, No.332347.Dame Hermina Boisjoly, plaintiff, vs J.Duhamel, defendant.NOTICE Dame Hermina Boisjoly, wife of J.Duhamel residing in Montreal, has instituted against her husband, an action for separation as to property.Montreal, April 30, 1953.True Copy.M.G.VADEBONCOEUR, 34847 Attorney for plaintiff.Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.332996.Dame Gertrude Paradis, plaintiff vs Edgar Milot, defendant.Dame Gertrude Paradis, of the City and District of Montreal, wife common as to property of Edgar Milot, Painting Contractor, of the same place, has instituted an action for separations as to property against her husband.Montreal, May 14, 1953.Les Procureurs de la demanderesse, CHAIT, KLEIN & ARONOVITCH, 34865 CHAIT, KLEIN & ARONOVITCH.34865-o Attorney for Plaintiff. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol 86, No.21 1723 Avis divers AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la Loi 11 George VI, chapitre 52, article 5, l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le douze mai 1953, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"Union Indépendante des Employés de Daoust, La-londe & Compagnie Limitée\", dont la formation a été autorisée le 25 octobre 1947, avec son siège social en la cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 13 mai 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34845-0 LUCIEN DARVEAU.Charrier & Dugal Limitée Sommaire du règlement spécial N° \"A\" Le règlement spécial N° \"A\" décrété par les directeurs de la Compagnie \"Charrier & Dugal Limitée\" et dûment sanctionné par .les actionnaires, pourvoit à la distribution de tout l'actif de cette compagnie proportionnellement aux actionnaires.Québec, P.Q., ce 13 mai 1953.(Sceau) Le Secrétaire, 34848-0 RAYMOND NADEAU.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat des Producteurs de Pommes de Terre du District des Trois-Rivières\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le quatre mai 1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Sainte-Marguerite des Trois-Rivières, dans le district judiciaire des Trois-Rivières.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34850-o LUCIEN DARVEAU.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat des Producteurs-Fournisseurs de Lait de la Laiterie Belanger-Dairy\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le six mai 1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Sainte-Flore, dans le comté de St-Maurice.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34851-o LUCIEN DARVEAU.Miscellaneous Notices NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that, in conformity with the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162, as added by the Act 11, George VI, chapter 52, section 5, the Honourable the Provincial Secretary under date of May twelfth, 1953, has enacted the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"Union des Employés de Daoust, Lalonde & Compagnie Limitée\", formation of which was authorized on October 25, 1947, with Its head office in the city of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, May 13, 1953.LUCIEN DARVEAU, 34845 Acting Under Secretary of the Province.Charrier & Dudal Limitée Summary of Special By-law No.\"A\" Special By-law No.\"A\" enacted by the Directors of the Company \"Charrier & Dugal Limitée\", and duly sanctioned by the shareholders, povides for a proportionate distribution to the shareholders, of all the assets of said Company.Quebec, P.Q., this 13th of May 1953.(Seal) RAYMOND NADEAU, 34848 Secretary.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat des Producteurs de Pommes de Terre du District des Trois-Rivières\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May fourth J953.The principal place of business of the said professional syndicate is at Sainte-Marguerite des Trois-Rivières, in the judicial district of Trois-Rivières.LUCDZN DARVEAU, 34850 Acting Under Secretary of the Province.NTTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat des Producteurs-Fournisseurs de Lait de la Laiterie Belanger-Dairy\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May sixth, 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at Sainte-Flore, in the county of St-Maurice.' LUCIEN DARVEAU, 34851 Acting Under Secretary of the Province. 1724 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 mai 1953, Tome 85, N° 21 Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le 4 mai 1953, les règlements, comprenant les articles 1 à 50 inclusivement, de \"La Ligue d'Action Civique \u2014 Civic Action League\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 6 mai 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34S49-o LUCIEN DARVEAU.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary approved, on May 4th, 1953, the by-laws, including articles 1 to 50 inclusive, of \"La Ligue d'Action Civique \u2014 Civic Action League\", and such, in conformity with the provisions of Section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretaro, the sixth dav of May 1953.LUCIEN DARVEAU, 34S49 Acting Under Secretary of the Province.Avis he Changement de Nom (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a autorisé, le sept mai 1953, le changement de nom de \"L'Association des Employés du Journal \"La Tribune\" de Sherbrooke\", dont la formation a été autorisée le 12 septembre 1950, et dont le siège social est situé à Sherbrooke, en celui de \"Syndicat de L'Imprimerie de Sherbrooke Inc.\", et ce, conformément aux dispositions des articles 7 et suivants de la Loi des syndicats professionnels (S.R.Q.1941, chapitre 102).Donné au bureau du Secrétaire de la province le huit mai 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34852-0 LUCIEN DARVEAU.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"The Bristol Aeroplane Engines Employees' Association\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le douze mai 1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34853-o LUCIEN DARVEAU.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de Christ-Roi de ChAteauguay\", en date du sept avril 1953, dont le siège social est situé à ChAteauguay-Bassin, dans le comté de ChAteauguay, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 17 avril 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34861-0 LUCIEN DARVEAU.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Tobcx Credit Union Limited\", en date du 1er mai 1953, dont le siège social est situé à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 12 mai 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34862-0 LUCIEN DARVEAU.Notice of Change of Name (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary, on May seventh, 1953, authorized the change of name of \"L'Association des Employés du Journal \"La Tribune\" de Sherbrooke\", the formation of which was authorized on September 12, 1950, and whose head office is situate at Sherbrooke, into that of \"Syndicat de l'Imprimerie de Sherbrooke Inc.\", and such, pursuant to the provisions of sections 7 and following of the Professional- Syndicates' Act, (S.R.Q., 1941, chapter 162).Given at the office of the Provincial Secretary, -this eighth dav of May, 1953.LUCIEN DARVEAU, 34852 Acting Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"The Bristol Aeroplane Engines Employees' Association\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May 12th, 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at Montreal, in the judicial district of Montreal.LUCIEN DARVEAU, 34S53 Acting Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de Christ-Roi de ChAteauguay\" under date the seventh day of April 1953, whereof the head office is at Chateauguay-Bassin, in the county of ChAteauguay, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Prlvincial Secretary, this April 17th, 1953.LUCIEN DARVEAU, 34861 Acting Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Tobex Credit Union Limited\" under date the 1st of May 1st, 1953 whereof the head office is at Montreal, in the judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, May 12, 1953.LUCIEN DARVEAU, 34862 Acting Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May SSrd, 1953, Vol 85, No.SI 1725 Viau Limitée \u2014 Viau Limited Règlement numéro deux Qu'il soit arrêté coniine règlement de la compagnie que le nombre d'administrateurs de la compagnie soit augmenté de six à sept et que les règlements de la compagnie soient amendés en conséquence.Certifié conforme.Le Secrétaire, 34863-0 ABEL FAFARD.Province de Québec, District de Montréal, Ville Mont-Royal Le règlement N° 349 pour fixer à trois ans la durée des fonctions du maire et des échevins.Lors d'une séance spéciale du Conseil ,de Ville Mont-Royal tenue le 28ième jour de février 1953 et à laquelle étaient présents: Son Honneur le Maire R.J.P.Dawson et les échevins: K.Aird, D.H.Kerr, E.E.Lanthier et Joan Storey étant le quorum du Conseil.Il est, par les présentes, ordonné et décrété comme étant le règlement X° 349 de Ville Mont-Royal ce qui suit: Article 1.Conformément aux dispositions de l'article 173a de la Loi des cités et villes (S.R.Q.1941, chapitre 233), telles (pic remplacées pour la Ville de Mont-Royal par les amendements à la charte de la ville passés à la première session de la vingt-quatrième Législature, 1-2 Elizabeth II, 1952-1953, la durée des fonctions du maire et des échevins est, par les présentes, fixée à trois ans à compter de l'élection subséquente.Article 2.Dans les années au cours desquelles le maire devra être élu, un échevin sera élu, et dans chcocune des deux années qui s'écouleront deux échevins seront élus; cependant, à l'élection générale de l'année 1953, un échevin sera aussi élu pour une durée de deux ans et à l'élection générale de l'année 1954 un échevin sera aussi élu pour une durée d'une année.L'échevin qui sera élu à chacune desdites années 1953 et 1954 pour une durée de moins que trois ans sera désigné au moyen d'un tirage au sort parmi les échevins dont la fonction se termine au cours de cette année.Article 3.Sujet à l'approbation des électeurs et à celle du Lieutenant-gouverneur en Conseil, telle que requise par le susdit article 173a, le présent règlement deviendra en vigueur et prendra effet à la date de l'élection générale de l'année 1953 et la durée de la votation sera celle fixée pour ladite élection./ Ce règlement a été approuvé par les électeurs le 1er avril 1953.Le Lieutenant-gouverneur en Conseil a donné son approbation audit règlement le 13 mai 1953.Le Maire, (Signé) R.J.P.DAWSON.Le Secrétaire-trésorier, 34864 D.W.LOUGH.avis de changement de nom Avis est par les présentes donné par le maire et le secrétaire-trésorier de la municipalité de la Partie Est du canton de Campbell, comté de Labelle, que le Lieutenant-Gouverneur en con- Viau Limitée Viau Limited By-law Number two That it be ordained as a by-law of the company that the number of directors of the company be increased from six to seven and that the by-laws of the company be amended in consequence thereof.Certified true copy.ABEL FAFARD, 34863 Secretary.Province of Quebec District of Montreal Town of Mount Royal By-law No.349 being a By-law to fix the term of office of the Mayor and Aldermen at three years.v \u2022 At a special sitting of the Council of the Town of Mount Royal, held on the 28th day of February, 1953 and at which were present: His worship Mayor R.J.P.Dawson and Aldermen: K.Aird, D.H.Kerr, E.E.Lanthier and Joan Storey being a quorum of the Council.It is hereby ordained and enacted as by-law No.349 of the Town of Mount Royal as follows: Article 1.Pursuant to the provisions of Section 173a of the Cities and Towns Act (R.S.Q.1941, Chapter 233) as replaced for the Town of Mount Royal by the Town's charter amendments passed at the First Session, twenty-fourth Legislature, 1-2 Elizabeth II, 1952-53 the term of office of the mayor and aldermen is hereby fixed at three years, as from the ensuing election.Article 2.In the years when the mayor is to be elected one alderman shall also be elected, and in each of the two intervening years two alderman shall be elected; however, at the general election in the year 1953 one alderman shall also be elected for a term of two years and at the general election in the year 1954 one alderman shall also be elected for a term of one year.The alderman to l»c elected in each of the said years 1953 and 1954 for a term of less than three years shall be designated by lot from amongst the aldermen whose term expires in that year.Article 3.Subject to approval by the electors and by the Lieutenant-Governor in Council as required by the aforesaid Section 173a, the present by-law shall come into force and effect on the date of the general election in the year 1953.The vote of the electors shall be taken at the same time as the general election is held in the year 1953 and the duration of the voting shall be that fixed for the said election.This by-law has been approved by the electors on April 1st, 1953.The Lieutenant-Governor in Council has given his approval to said by-law on May 13th, 1953.(Signed) R.J.P.DAWSON, Mayor.D.W.LOUGH, 34864-0 Secretary-Treasurer.' Notice of change of name Notice is hereby given by the Mayor and Secretary-Treasurer of the municipality of the Eastern Part of the Township of Campbell, county of Labellc, that the Lieutenant-Governor 1726 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 mai 1958, Tome 85, N° 21 seil a approuvé, en date du 30 avril 1953, suivant un rapport du Comité de l'honorable Conseil exécutif, le changement du nom de \"la municipalité de la partie est du canton de Campbell \"en celui de \"la municipalité du Lac des Ecorces\", comté de Labelle.Conformément aux dispositions de l'article 48 du code municipal, ce changement de nom entre en vigueur à compter de la date de la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Lac des Ecorces ce 9e jour de mai 1953.Le Maire, J.E.BROUSSEAU.Le Secrétaire-trésorier, 34866-0 VICTOR PÀQUETTE, in Council, on April 30, 1953, following a report of the Committee of the Honourable Executive Council, approved the change of name of \"La municipalité de la partie est du canton de Campbell\" into that of \"La municipalité du Lac des Ecorces\", county of Labelle.Pursuant to the provisions of Article 48 of the Municipal Code, this change of name will come into force, as from the date of the publi-tion of this said notice in the Quebec Official Gazette.Lac des Ecorces, this ninth dav of May 1953.J.E.BROSSEAU, Mayor.VICTOR PAQUETTE, 34866 Secretary-Treasurer.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Coopérative Progressive de Construction\", en date du 14 mai 1953, dont le siège social est situé à Québec, dans le district judiciaire de Québec, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 16 mai 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34874-0 LUCIEN DARVEAU.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Cooperative Progressive de Construction\" under date the 14th day of May, 1953 whereof the head office is at Quebec, judicial district of Quebec, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 16th day of May, 1953.LUCIEN DARVEAU, 34874 Acting Under Secretary of the Province.Avis de Changement de Nom (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable secrétaire de la Province a autorisé, le six mai 1953, le changement de nom de \"Le Syndicat National des Compagnons et Artisans Barbiers, Coiffeurs et Coiffeuses de Sorel Inc.\", dont la formation a été autorisée le premier décembre 1952, et dont le siège social est situé à Sorel, en celui de \"Syndicat National des Barbiers Coiffeurs et Coiffeuses de Sorel Inc.\", et ce, conformément aux dispositions des articles 7 et slivants de la Loi des syndicats professionnels (S.R.Q.1941,' chapitre 162).Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 7 mai 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34876-0 LUCD2N DARVEAU.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"L'Association Patronale des Barbiers et Coiffeurs du District de Thetford Mines Inc.\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le vingt-neuf avril 1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Thetford-Mines, dans le district judiciaire d'Arthabaska.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34877-0 LUCIEN DARVEAU.Notice of Change of Name (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary, on May sixth, 1953, authorized the change of name of \"Le Syndicat National des Compagnons et Artisans Barbiers, Coiffeurs et Coiffeuses de Sorel Inc.\", the formation of which was authorized on December first, 1952, and whose head office is situate at Sorel, into that of \"Syndicat National des Barbiers Coiffeurs et Coiffeuses de Sorel Inc.\", and such, pursuant to the provisions of sections 7 and following of the Professional Syndicates' Act, (R.S.Q., 1941, chapter 162).Given at the office of the Provincial Secretary, this 7th day of May, 1953.LUCIEN DARVEAU, 34876 Acting Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"L'Association Patronale des Barbiers et Coiffeurs du District de Thetford Mines Inc.\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on April twenty-ninth, 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at Thetford Mines, judicial District of Arthabaska.LUCIEN DARVEAU, 34877 Acting Under Secretary of the Province.Avis est par les présentes donne que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Syndicat Coopératif de Téléphone St-Fabien \u2014 Ste-Lucie ', en date du Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate.\"Syndicat Coopératif de Téléphone St-Fabien \u2014 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 196S, Vol.85, No.21 1727 13 mai 1953, dont le siège social est situé à Saint-Fabien-de-Panet, dans le comté de Montmagny, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du \"\"Secrétaire de la Province le 19 mai 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34880-o LUCIEN DARVEAU.Avis de changement de nom (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a autorisé, le vingt-neuf avril 1953, le changement de nom de \"L'Union des Institutrices du Diocèse de Rimouski\", dont le siège social est situé à Rimouski, en celui de \"Le Syndicat Régional des Institutrices de Rimouski\", et ce, conformément aux dispositions des articles 7 et-suivants de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 30 avril 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34886 LUCIEN DARVEAU.Province de Québec Syndics de la paroisse de Saint-Jérôme de Lac Saint-Jean Avis de rachat d'obligations Avis est donné, par les présentes, qu'aux termes de l'acte de fiducie par les Syndics de la paroisse de Saint-Jérôme de Lac Saint-Jean en faveur de la Société Nationale de Fiducie, exécuté devant Me Oscar Hamel, notaire, le 23 août 1939, lesdits Syndics rachèteront le 1er juillet 1953, au prix de 100% de leur valeur nominale et l'intérêt couru, $5,000.00 d'obligations faisant partie de leur émission de $153,500.00 savoir: 3x1000 \u2014 Nos AM-12, 22 et 35 3 x 500 \u2014 Nos AD-Z8, 25 et 80 5 x 100 \u2014 Nos AC-9, 43, 60, 66 et 85 Les porteurs des obligations ci-dessus mentionnées devront, le 1er juillet 1953, présenter les dites obligations pour paiement à la Banque Canadienne National, à Saint-Jérôme, Chicou-timi, Québec, ou Montréal, avec le coupon d'intérêt du 1er juillet 1953 et les coupons subséquents.Lesdites obligations cesseront de porter intérêt à compter du 1er juillet 1953.Montréal, ce 19 mai 1953.Société Nationale de Fiducie, Fiduciaire.Le Secrétaire, H.OUIMET.41 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal 1 34887-o Ilgwu Centre Inc.Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs Règlement N° XX Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Ilgwu Centre Inc.ce qui suit: Ste-Lucie\" under date the thirteenth day of May 1953, whereof the head office is at Saint-Fabien-de-Panet, in the county of Montmagny and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this nineteenth day of May 1953.LUCIEN DARVEAU, 34880 Acting Under Secretary of the Province.Notice of Change of Name (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that, the Honourable Provincial Secretary has authorized under date of April twenty-ninth, 1953, the change of name fo \"L'Union des Institutrices du Diocèse de Rimouski\", whose head office is situate at Rimouski into that of \"Le Syndicat Régional des Institutrices de Rimouski,\" and such, pursuant to the Provisions of sectihns 7 and follawing of the Professional Syddicates* Act, R.S.Q., 1941, chapter 102.Given at the Office of the Provincial Secretary, April 30th, 1953.LUCIEN DARVEAU, 34886 Acting Under Secretary of the Province.Province of Quebec Trustees of the Parish of Saint Jérôme of Lake St.John Notice of Redemption Notice is hereby given that pursuant to the provisions of the Trust Deed by the Trustees of the parish of Saint Jérôme of Lake Saint John in favor of the Société National de Fiducie, passed before Notary Oscar Hamel, on August the 23rd, 1939, said Trustees will redeem before maturity on, the first day of July 1953, at par and accrued interest, $5,000.00 principal amout of bonds being part of their issue of $153,500.00, viz: 3 x 1000 \u2014 Nos AM-12, 22 and 35 3 x 500 \u2014 Nos AD-18, 25 and 80 5 x 100 \u2014 Nos AC-9, 43, 60, 66 and 85 The holders of the above mentioned bonds shall, on the first of July 1953, present the said bonds for payment at the Banque Canadienne Nationale, at Saint Jôréme, Chicoutimi, Quebec or Montreal, with interest coupon maturing on the first of July 1953, and following coupons.The said bonds will cease to bear interest on and from the first of July 1953.Montreal, this 19th day of May 1953.Société Nationale de Fidicie, Trustee.H.OUIMET, Secretary.41 West, St-James Street, Montreal 1.34887-o Ilgwu Centre Inc.By-law to increase number of Directors By-law No.XX Be it enacted and it is hereby enacted as a By-law of \"Ilgwu Centre Inc., as follows: 1728 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 mai 1953, Tome 85, N° 21 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de sept à dix tie manière à ce que le bureau de direction tie la compagnie soit composé dorénavant de tlix directeurs.2° Que sept directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3° Que tous les règlements, résolutions et procédures antérieurs tie la compagnie incompatibles à icelui soient, par les présentes, amendés, modifiés et revisés pour donner effet à ce règlement.Décrété ce 20ième jour tie mars 1953.Le Président, BERNARD SHANE.Le Secrétaire, M.McMARTIN.Certifié vraie copie du règlement N° XX décrété par les directeurs le 20ième jour de mars 1953, et confirmé à l'unanimité par les actionnaires le 20ième jour de mars 1953.(Sceau) Le Secrétaire, 34890 M.McMARTIN.1.The number of directors of the company be and the same is hereby incrcasctl from seven to ten so that the Board of Directors of the Company shall hereafter be composed of ten directors.2.That seven directors shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors.3.That all prior By-laws, resolutions antl proceedings of the company, inconsistent herewith are hereby amended, modified antl revised in order to give effect to this By-law.Enacted this 20th day of March, 1953.BERNARD SHANE, President.M.McMARTIN, Secretary.Certified to be a true copy of By-law No.XX enacted by the Directors on the 20th day of March, 1953, and unanimously confirmed by the Shareholders on the 20th dav of March, 1953.(Seal) M.McMARTIN, 34890-o Secretary.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"L'Association des Commis des Cantons de l'Est\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le vingt mai.-1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Sherbrooke, dans le district judiciaire de St-François.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34891-o LUCIEN DARVEAU.AVIS Copie certifiée du règlement spécial \"A\" de Trans-Canada Chemicals, Inc., adopté à une assemblée des directeurs de Trans-Canada Chemicals, Inc., tenue le 24e jour d'avril 1953, et approuvé à l'unanimité, ratifié et confirmé à une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie, tenue à son siège social le 24 avril 1953.Règlement spécial \"A\" Que le nombre des directeurs de la compagnie soit augmenté de cinq à sept et que le règlement 11 des règlements généraux de la compagnie soit et il est, par les présentes, amendé en changeant le mot \"cinq\" pour \"sept\".Montréal, P.Q., le 11 mai 1953.Certifié vraie copie.(Sceau) Le Secrétaire, 34896 MARCEL PICHÉ, C.R.Arrêté en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 586 Québec, le 13 mai 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil Concernant la soustraction au jalonnage en NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"L'Association des Commis des Cantons de l'Est\" for the study, defence and promotion of the economic, social antl moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May twentieth, 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at Sherbrooke, in the judicial district of St.Francis.LUCIEN DARVEAU, 23891 Acting Under Secretary of the Province.NOTICE Certified copy of special by-law \"A\" of Trans-Canada Chemicals, Inc., adopted at a meeting of the Directors of Trans-Canada Chemical, Inc., held on the 24th day of April 1953, and unanimously approved, ratified and confirmed at a special general meeting of shareholders of the Company, held at its bead office on April 24th., 1953.Special By-Law \"A\" That the number of Directors of the Company be increased from five to seven and that By-law 11 of the General By-laws of the Company be and it is hereby amended by changing the word \"five\" to \"seven\".Certified true copy.Montreal, P.Q., May 11th, 1953.(Seal) MARCEL PICHÉ, Q.C., 34896-0 Secretary.Order in Council ORDER IN COUNCIL CHAMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL Number 586 Quebec, May 13, 1953.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the withdrawal of staking of min- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol 86, No.21 1729 claims miniers AVIS Avis est par les présentes donné que \"Tabah Trading Company Limited\" fera application au Procureur-Général de la Province de Québec pour permission d'abandonner la Charte de la Companie en vertu de l'Acte des Companies de Québec.Montréal, 12ieme mai 1953.Les Procureurs pour Tabah Trading Company Limited, 34856-0 CHAIT KLEIN & ARONOVITCH.Compagnies dissoutes NOTICE Notice is hereby given that \"Tabah Trading Company Limited\" will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender the Charter of the Company under the provisions of the Quebec Companies' Act.Montreal, May 12th, 1953.CHAIT KLEIN & ARONOVITCH, Attorneys for 34850-o Tabah Trading Company Limited.Companies Dissolved Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrété par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Belvedere Insurance Agency Inc.\u2014 L'Agence d'Assurance Belvedere Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 20 février 1952.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze mai 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 16 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34845-0 L.DÊSHvETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général, d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Benjamin Moore & Co.of Montreal Limited\" constituée en corporation, par lettres patentes en date du 10e jour de décembre 1927.Avis est de plus donné qu'à compter du quinzième jour de mai 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 16e jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34845 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la corporation \"Comité de Secours et de Reconstruction de Cabano Inc.\", constituée en corpo- Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been peased to accept the surrender of the charter of the company \"Belvedere Insurance Agency Inc.\u2014 L'Agence d'Assurance Belvedere Inc.\", incorporated by letters patent dated February 20, 1952.Notice is also given that from and after May fifteenth 1953, the said company has been dissolved.¦ Dated at the office of the Attorney General, May sixteenth, 1953.L.DÉSILETS, 34845 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Benjamin Moore & Co.of Montreal Limited\", incorporated by letters patent dated the 10th day of December, 1927.Notice is also given that from and after the fifteenth day of May, 1953, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the 16th day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34845-o Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 176, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of che said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the corporation \"Comité de Secours et de Reconstruction de Cabano Inc.\", incorporated QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol.86, No.21 1731 ration en vertu de la troisième partie de ladite loi, par lettres patentes en date du 3 octobre 1950.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze mai 1953, ladite corporation a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 16 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34845-0 L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général, d'accepter l'abandon de la charte de la compa-' gnie, \"Forest Lock Co.Ltd.\" constituée en corporation par lettrex patentes en date du 9e jour de janvier 1952.Avis est de plus donné qu'à compter du quinzième jour de mai 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 16e jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34845 L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Freed Paper Box Manufacturing Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 3e jour d'avril 1930.Avis est de plus donné qu'à compter du quinzième jour de mai 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du procureur général, ce 16e jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34845 L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, R.S.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général, d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"H.J.McAdie Company Ltd.\" constituée en corporation par lettres pateutes en date du 17e jour de janvier 1944.Avis est de plus donné qu'à compter du quinzième jour de mai 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 16c .jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34845 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \" Les Produits Laitiers Laurentide Limitée \u2014 Laurentide Dairy Products Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 9 octobre 1941.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze mai 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 16 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34845-o L.DÉSILETS.by letters patent dated October 3rd, 1950, under Part III of the said Act.Notice is also given that from and after May fifteenth 1953, the said corporation has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, May sixteenth 1953.L.DÉSILETS, 34845 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject'to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Forest Lock Co.Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 9th day of January, 1952.Notice is also given that from and after the fifteenth day of May, 1953, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the 16th day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34845-o Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I o* the Quebec Companies' Act, Revised Statutes o* Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Freed Paper Box Manufacturing Company Limited\", incorporated by letters patent dated the 3rd day of April, 1930.Notice is also given that from and after the fifteenth day of May, 1953, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the 16th day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34845-0 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"H.J.McAdie Company Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 17th day of Januarv, 1944.Notice is also given that from and after the fifteenth day of May, 1953, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the 16th day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34S45-0 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Les Produits Laitiers Laurentide Limitée\u2014 Laurentide Dairy Products Limited\", incorporated by letters patent dated October 9, 1941.Notice is also given that from and after May fifteenth 1953, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, May sixteenth 1953.L.DÉSILETS, 34845 Deputy Attorney General. 1732 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S3 mai 1953, Tome 85, N° SI Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général, d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Ottawa River Development Company\" constituée en corporation, par lettres patentes en date du 29e jour de novembre 1930.Avis est de plus donné qu'à compter du quinzième jour tie mai 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 16e jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34845 L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général, d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \" Speyer Diamond Import Co.Ltd.\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 20e jour de juillet 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du quinzième jour de mai 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 16e jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34845 L.DÉSILETS.Département de l'Instruction publique Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of t.he charter of the company \"Ottawa River Development Company\", incorporated by letters patent dated the 29th day of November, 1930.Notice is also given that from and after the fifteenth day of May; 1953, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the 16th day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34835-o Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I o the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Speyer Diamond Import Co.Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 20th day of July, 1945.Notice is also given that from and after the fifteench day of May, 1953, the said Company has been dissolved; Dated at the office of the Attorney General the 16th day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34845-0 Deputy Attorney General.Department of Education N° 151-52.Québec, 2 mai 1953.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Bristol, dans le comté de Pontine, et d'annexer à la municipalité scolaire protestante de Clarendon, dans le même comté, le territoire décrit comme suit: Les lots 1 à 8 inclusivement du rang I, les lots 1 à 6 inclusivement du rang II et les lots 1 à 5a inclusivement du rang IIJ du canton Bristol.L'annexion s'applique aux contribuables protestants seulement.Le Surintendant de l'Instruction publique, 34828-20-2 O.J.DESAULNIERS.N° 116-53.Québec, le 11 mai 1953.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Saint-Ferdinand, dans le comté de Mégantic, le territoire ci-dessous décrit et de l'annexer, pour les contribuables protestants seulement, à la municipalité scolaire protestante d'Inverness, dans le même comté, savoir: Dans le canton d'Halifax-Sud, les lots suivants, tous inclusivement: 1 à 16 en y incluant le village de Bernierville, dans le rang VTI (7); les lots 1 à 16 des rangs Vin, IX et X (8, 9 et 10) et les lots 1 à 11 du rang XI (11).Le Surintendant de l'Instruction publique, 34840-20-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 528-52.Québec, le 19 mai 1953.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en consei', par arrêté ministériel en date du 7 mai 1953, de détacher de la municipalité scolaire de Campbell's Bay, dans le comté de Pon- No.151-52.Quebec, May 2, 1953.\"Application is made to detach from the school municipality of Bristol, in the County of Pontiac, and annex to the Protestant school municipality of Clarendon, in the same County, the territory described as follows: Lots 1 to 8, inclusive, of Range I, lots 1 to 6, inclusive, of Range II, and lots 1 to 5a, inclusive of Range III of Bristol Township.\"The annexation to apply to Protestant taxpayers only.\" Superintendent of Education, 34828-20-2-o O.J.DESAULNIERS.No.116-53.Quebec, May 11, 1953.Application is made to detach from the school municipality of Saint-Ferdinand, in the county of Megantic, the territory hereunder described and to annex it, for protestant taxpayers only, to the protestant school municipality of Inverness, same county, to wit: In the township of Halifax-South, the following lots, all inclusive: 1 to 16 including the village of Bernierville, Range Vn (7); lots 1 to 16, Ranges VUI, IX and X (8, 9 and 10) and lots 1 to 11, Range XI (11).O.J.DESAULND3RS, 34840-20-2 Superintendent of Education1.No.528-52-.Quebec, May 19, 1953.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, has been oleased, by Order in Council, dated May 7th, 1953, to detach from the school municipality of Campbell's Bay, in the county QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol 85, No.21 1733 tiac, pour les annexer à la municipalité scolaire de Mansfield, dans le même comté, les lots 1 à 10 inclusivement des rangs V (5) à XI (11) aussi inclusivement du canton de Litchfield.Cette annexion s'appliquera pour les contribuables protestants seulement et prendra effet le premier juillet 1953.Le Surintendant de l'Instruction publique, 34882-0 O.J.DESAULNIERS.N° 1342-52.Québec, le 19 mai 1953.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 7 mai 1953, de détacher de la municipalité scolaire de Saint-Charles-Borromée, dans le comté de Joliette, les lots du cadastre officiel de ladite paroisse portant les numéros suivants, tous inclusivement : 54 à 68; 70 à 82 et 89, et qu'ils soient annexés à la municipalité scolaire de la Ville de Joliette, dans le même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet le 1er juillet 1953.Le Surintendant de l'Instruction publique, 34882-0 O.J.DESAULNIERS.N° 608-53.Québec, le 20 niai 1953.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Ste-Thérèse Ouest, dans le comté de Terrebonne, les lots 163 et 167, du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Thérèse, et de les annexer à la municipalité scolaire de St-Augustin, dans le comté des Deux-Montagnes.Le Surintendant de l'Instruction publique, 34884-21-2-0 O.J.DESAULNIERS.N° 424-53.Québec, le 20 mai 1953.Demande est faite de former une municipalité scolaire distincte, pour les catholiques seulement, sous le nom de \"La municipalité scolaire catholique de Saint-Lambert, dans le comté de Chambly\".Le territoire de cette municipalité comprend tous les lots indiqués ci-dessous qui font partie du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, savoir: Cedit territoire est borné comme suit: A l'ouest, par le fleuve St-Laurent, à partir de la ligne nord-est du chemin Tiffin et, de là, dans une direction sud jusqu'à la ligne ouest du lot N° 264: de là, dans une direction est le long de la ligne de division entre les lots N° 264 et 265 jusqu'à la ligne ouest du lot N° 308; de là, dans une direction sud, le long de la ligne de division ouest enT tre les lots 308 et 265-266, jusqu'à la ligne de division entre les lots N° 266 et 267; de là, dans une direction est, le long de la ligne de division entre les lots 266 et 267 et les N° 273 et 274, jusqu'à la ligne latérale sud-ouest du chemin Lapinière; de là, dans une direction nord-ouest, le long de la ligne sud-ouest du chemin Lapinière, jusqu'à la ligne de division des lots N° 273 et 272; de là, vers l'ouest le long de la ligne de division entre les lots N° 272 et 273 et les lots 265 et 266; de là, jusqu'à la ligne de division est entre les lots N° 265 et 308; de là, vers le nord, le long de la ligne de division est entre les lots N° 265 et 308, jusqu'à la ligne de division entre les lots 264 et 265; de là, vers l'est le long de la ligne de division entre les lots N° 264 et 265 et les lots N°272 et 271, jusqu'au chemin Lapinière; de là, vers le nord-ouest, le long de la ligne sud-ouest du chemin Lapinière, jusqu'à un point à cent pieds au sud-est de la ligne de division entre les lots N° 247 et 246; de là, vers le nord-est, le long de la of Pontiac, to annex them to the school municipality of Mansfield, in the same county, lots 1 to 10 inclusively of ranges V (5) to XI (11) also of the Township of Litchfield inclusively.This annexation will apply for the Protestant taxpayers only and will take effect on July 1st, 1953.O.J.DESAULNIERS, 34882 Superintendent of Education.No.1342-52.Quebec, May 19, 1953.His Honour the Lieutenant-Governor in Council by Order in Council dated May 7, 1953, has been pleased to detach from the school municipality of Saint-Charles-Borromée, in the county of Joliette, lots of the official cadastre of the said parish bearing the following numbers all inclusive: 54 to 68; 70 to 82 and 89, and that they be annexed to the school municipality of the Town of Joliette, same county.This order in Council shall come into effect on July First, 1953.O.J.DESAULNIERS, 34882 Superintendent of Education.No.608-53.Quebec, May 20, 1953.Application is made to detach from the school municipality of Ste-Thérèse, West, in the county of Terrebonne, lots 163 and 167, of the official cadastre of the parish of Ste.Thérèse, and to annex them to the school municipality of St.Augustin, in the county of Two-Mountains.O.J.DESAULNIERS, 34884-21-2 Superintendent of Education.No.424-53.Quebec, May 20, 1953.Application is made to form a separate school municipality, for Catholics only, under the name of \"The Catholic School Municipality of Saint-Lambert, in the county of Chambly\".The territory of this municipality will be comprised of all the lots below indicated which form part of the official cadastre of the parish of Saint-Antoine de Longueuil, to wit: The said territory is bounded as follows: on the west, by the St.Lawrence River, starting from the northeast line of the Tiffin Road and thence, in a southerly direction as far as the western line of lot No.264; thenc, in an easterly direction along the division line between lots Nos.264 and 265 as far as the western line of lot No.308; thence, in a southerly direction, along the west division line between lots 308 and 265-266, as far as the division line between lots Nos.266 and 267; thence, in an easterly direction, along the division line between lots 266 and 267 and Nos.273 and 274.as far as the lateral southwest of the Lapinière Road; thence, in a northwesterly direction, along the southwestern line of the Lapinière Road, as far as the division line of lots Nos.273 and 272; thence, on the west along the division line between lots Nos.272 and 273, and lots 265 and 266; thence, as far as the east division line between lots Nos.265 and 308; thence, on the north, along the east division line between lots Nos.265 and 308, as far as the division line between lots 264 and 265; thence, on the east, along the division line between lot Nos.264 and 265 and lots Nos.272 and 271, as far as Lapinière Road; thence, on the northwest, along the southwestern line of the Lapinière Road to a point one hundred feet southeast of the division line between lots Nos.247 and 246; thence, on 1734 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 mai 1953, Tome 86, N° 21 ligne située à cent pieds au sud-est de la ligne de division entre les lots 247 et 246 jusqu'au chemin de la concession du Petit Bois; de là, vers le nord, le long dudit chemin, jusqu'à la ligne nord-est du chemin connu sous le nom de montée Tiffin; de là, le long de la ligne nord-est du chemin Tiffin, jusqu'au fleuve St-Laurent, au point de départ; le tout situé dans le comté de Chambly et comprenant environ mille cent quatre-vingt-douze acres et cinq dixièmes, mesures anglaises.Ledit territoire comprend aussi cette portion du lit des eaux et des îles du fleuve St-Laurent dont le périmètre se décrit comme suit: Partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent (faisant à cet endroit la limite ouest actuelle de la cité) avec la ligne nord-est du chemin Tiffin; de là, suivant le prolongement de ladite ligne nord-est du chemin Tiffin jusqu'au milieu du fleuve St-Laurent où il intcrscctc la limite de la cité de Montréal; de là, en allant vers le sud, suivant le milieu du fleuve Saint-Laurent (limite de la cité de Montréal jusqu'au prolongement de la ligne de division entre lçs lots N° 264 et 265; de là, allant vers l'est suivant ledit prolongement jusqu'à la rive du fleuve Saint-Laurent (limite ouest actuelle de la cité); de là, allant vers le nord, suivant la rive du fleuve Saint-Laurent (limite ouest actuelle de la cité), jusqu'au point de départ.L'Ile Sainte-Hélène, l'île Verte et l'île Ronde ne sont pas comprises dans le territoire de la cité.Le Surintendant de l'Iustruction publique, 34885-21-2-0 0.J.DESAULNIERS.Québec, 20 mai 1953.Demande est faite d'annexer à la municipalité scolaire protestante du village de Gaspé, dans le comté de Gaspé-Sud, le territoire de la municipalité scolaire de Baie de Gaspé Sud et le territoire de la municipalité scolaire de York, dans le même comté, et d'ériger en une municipalité scolaire séparée et distincte, pour les protestants seulement, sous le nom de \"Municipalité scolaire protestante de Gaspé, comté de Gaspé-Sud\", le territoire de ces trois municipalités, lequel est décrit comme suit: Tout le territoire de la municipalité du village de Gaspé composé du lot 1 au lot 150 inclusivement, avec toutes les subdivisions suivant le plan cadastral officiel du village de Gaspé.Tout le territoire de la municipalité de Douglas-Ouest, lequel est décrit comme suit: Les lots A, B C et le lot Al au lot 11 inclusivement du premier rang de Sandy Beach: les lots A à 13 inclusivement du premier rang de Haldi-mand: les lots 1 à 4 inclusivement du deuxième rang nord: les lots 1 à 5 inclusivement du deuxième rang sud, comprenant toutes les subdivisions des lots et rangs sus-mentionnés, suivant le plan cadastral officiel de la municipalité de Douglas-Ouest.Les lots 6A à 49 inclusivement et les îles A, B, C et E du rang I du canton de Baie Gaspé Sud: les lots 1 à 21 inclusivement du rang TL du canton de Baie Gaspé Sud: les lots 1 à 22 inclusivement du rang III du canton de Baie Gaspé Sud: les lots 1 à 17 inclusivement du rang central du canton de Baie Gaspé Sud: les lots E et F et les lots 1 à 68 inclusivement, les îles A à J inclusivement et les îles 27 à 30 inclusivement du rang Dartmouth, comprenant toutes les subdivisions des rangs, lots et îles sus-mention- the northeast, along the line situate at one hundred feet to the southeast of the division line between lots 247 and 246 as far as the concession road of the \"Petit Bois\"; thence, on the north, along the said road, as far as the line northeast of the road known under the name of Tiffin height; thence; along the line northeast of Tiffin Road, as far as the St.Lawrence River, to the starting point; the whole situate in the county of Chambly and comprising about oue thousand one hundred and ninety-two acres and five-tenths, English measure.The said territory also is comprised of that portion of the river-bed and the islands of the St.Lawrence River, the perimeter of which is described as follows: starting from the point of intersection of the St.Lawrence, river bank (forming at this place the present western limit if the City) with the northeasterly line of the Tiffin Road; thence, following the prolongation of the said northeasterly line of the Tiffin Road to the middle of the St-Lawrence River where it intersects the limit of the City of Montreal; thence, going towards the south, following the middle of the Saint Lawrence River (limit of the City of Montreal) as far as the prolongation of the division line between lots Nos.264 and 265; thence, going towards the cast following the said prolongation as far as the bank of the Saint Lawrence River (present western limit of the City) ; thence, going towards the north, following the bank of the Saint-Lawrence River (present western limit of the City), to the starting point.St.Helen's Island, L'île Verte and l'île Ronde are not comprised in the territory of the City.O.J.DESAULNIERS, 34SS5-21-2 Superintendent of Education.Quebec, May 20th, 1953.Application is made to annex to the Protestant school municipality of Gaspé Village, in the County of Gaspé South, the territory of the school municipality of Gaspé Bay South and the territory of the school municipality of York, in the same County, and to erect into a separate and distinct school municipality for Protestants only, under the name of \"the Protestant school municipality of Gaspé, in the County of Gaspé South\", the territory of these three municipalities which is described as follows: \"All the territory of the municipality of the Village of Gaspé winch is lot 1 to lot 150, inclusive, with all the subdivisions according to the official cadastral plan of the Village of Gaspé.\"All the territory of the municipality of Douglas West which is described as follows: \"Lots A, B, C and lot Al to lot 11, inclusive, of the First Range of Sandy Beach: lots A to 13, inclusive, of the First Range of Haldimand; lots 1 to 4, inclusive, of the Second Range north; lots 1 to 5, inclusive, of the Second Range south, including all subdivisions of the aforementioned lots and Ranges according to the official cadastral plan of the municipality of Douglas'West.\"Lots 6A to 49, inclusive, and Islands A, B, C and E of Range I in the Township of Gaspé Bay South; lots 1 to 21, inclusive, of Range II in the Township of Gaspé Bay South: lots 1 to 22, inclusive, of Range ni in the Township of Gaspé Bay South: lots 1 to 17, inclusive, of the Central Range of the Township of Gaspé Bay South; lots E and F and lots 1 to 68, inclusive, Islands A to J, inclusive, and Islands 27 to 30, inclusive, of the Dartmouth Range, including all subdivisions of the aforementionee Ranges, lots QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 2Srd, 1953, Vol 85, No.21 1735 nés du canton de Baie Gaspé Sud, suivant le plan cadastral officiel.Le territoire suivant, dans le canton de York, comté de Baie de Gaspé-Sud: Les lots A et C, les l(>ts 1 à 21 inclusivement et les îles D, F et G du rang I: les lots 1 à 56 inclusivement du rang II: les lots 1 à 56 inclusivement du rang III: les lots à 1 57 inclusivement du rang IV; les lots 1 à 18 inclusivement du rang A: les lots 1 à 14 inclusivement et les iles K à Q inclusivement du rang York River.Ce territoire comprend toutes les subdivisions des rangs, lots et îles sus-mentionnés, suivant le plan cadastral officiel du canton de York.Le Surintendant, 34899-21-2 O.J.DESAULNIERS.and Islands in the Township of Gaspé Bay South according to the official cadastral plan.\"The following territory in the Township of York, in the County of Gaspé Bay South: \"Lots A and C, lots 1 to 21, inclusive, and Islands 1), F and G in Range I: lots 1 to 56, inclusive, of Range II: lots 1 to 56, inclusive, of Range III: lots 1 to 57, inclusive, in Range IV: lots 1 to 18, inclusive, in Range A; lots 1 to 14, inclusive, and Islands K to Q, inclusive, in York River Range.This territory includes all sub-divisions of the aforementioned Ranges, lots and Islands according to the official cadastral plan of the Township of York.\" O.J.DESAULNIERS, 34899-2 l-2-o Superintendent.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre Officiel de la Paroisse de Beauport (maintenant Ville de Beauport) Division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que une partie des lots 531-26 et 531-27, le lot 531-27-24, une partie du lot 531 sont annulés et les lots 1524 et 1525 sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 4 mai 1953.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, J.-E.GUAY, 34846-0 Sous-Ministre-ad joint.AVIS Cadastre Officiel du Village Incorporé de Longueuil (Cité de Longueuil) Division d'enregistrement de Chambly Avis est par la présente donné que les lots 199-228, 199-90 à 199-99, 200-212, 200-346 à 200-356, 200-391 à 200-401, partie des lots 200-212 et 200-214 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 11 mai 1953.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, J.-E.GUAY, 34846-0 Sous-Ministre-ad j.AVIS Cadastre Officiel de la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges Division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 4-37 à 4-153, 4-220 à 4-345, 4-399 à 4-531, 4-569 à 4-596, 4-596-A, 4-597 à 4-6Ô8, 4-709 à 4-7.24, 4-731 à 4-799, 4-803 à 4-807, 4-822 à 4-843, 4-844, 4-845, 4-862 à 4-867, 10-C, 10-D, 10-E, 10-F sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 4 mai 1953.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, J.-E.GUAY, 34846-0 Sous-Ministrc-adj.Department of Lands and Forests NOTICE \u2022 Official Cadastre of the Parish of Beauport (Now Town of Beauport) Registration Division of Quebec.Notice is hereby given that part of lots 531-26 and 531-27, lot 531-27-24, part of lot 531 are cancelled and lots 1524 and 1525 are added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, May the 4th, 1953.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, J.-E.GUAY, 34846-0 Asst.-Deputy Minister.NOTICE Official Cadastre of the Iicorporated Village of Longueuil (City of Longueuil) Registration Division of Chambly Notice is hereby given that lots 199-228, 199-90 to 199-99, 200-212, 200-346 to 200-356, 200-391 to 200-401, part of lots 200-213 and 200-214 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, May the 11th, 1953.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, J.-E.GUAY, 34846-0 Asst.-Deputy-Minister.NOTICE Official Cadastre of the Parish of Notre-Dame-des-Anoes Notice is hereby that lots 4-37 to 4-153, 4-220 to 4-345, 4-399 to 4-531, 4-569 to 4-596, 4-596-A, 4-597 to 4-688, 4-709 to 4-724, 4-731 to 4-799, 4-803 to 4-807, 4-822 to 4-843, 4-844, 4-845, 4-862 to 4-867, 10-C, 10-D, 10-E, 10-F are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, May the 4th, 1953.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, J.-E.GUAY, 34846-0 Asst.-Deputy Minister. 1736 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, S3 mai 1953, Tome 85, N° SI AVIS Cadastre Officiel du Village de Ste-An ne- de-Ch i cout i m i Division d'enregistrement de Chicoutimi Avis est par la présente donné que les lots 44-35 (rue) à 44-42, 57-23, 57-30 à 57-32 sont annulés et le lot 57-24 (rue) est corrigé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le premier mai 1953.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, J.-E.GUAY, 34846-0 Sous-Ministre-ad j.NOTICE Official Cadastre of the Village of Ste.Anne-de-Chicoutimi Registration Division of Chicoutimi Notice is hereby given that lots 44-35 (street) to 44-42, 57-23, 57-30 to 57-32 are cancelled and lot 57-24 (street) is corrected in virtue of Article 2174A of the civil Code.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, Quebec, May the lrst, 1953.J.-E.GUAY, 34846-0 Asst.-Deputy Minister.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la construction dans la cité de St-Jean et la ville d'Iberville, rendue obligatoire par le décret numéro 329 du 20 février 1947, lui ont présenté une requête à l'effet d'amender ledit décret, dans sa teneur modifiée, de la façon suivante: 1° L'article III sera remplacé par le suivant: \"III.Taux de salaire minima: Les taux de salaires minima suivants doivent être payés: Taux Métiers: horaires Ajusteur de gicleurs.$1.45 Briqueteur, plâtrier (travaux ordinaires ou d'ornementation), maçon ,y compris le tailleur sur le chantier, poseur de blocs de ciment, tireur de joints.1.62 Calf at.1.35 Charpentier, menuisier, mécanicien dans la construction, y compris les opérations suivantes: formes à béton (boutique ou chantier), posage de paravents (bois ou métal), châssis, fenêtres,\"weatherstrips\" bardeau (bois ou amiante ou composition), divisions en acier ameublements, tels que comptoirs et tablettes (fixes ou mobiles), tout papier composition, y compris le posage de plancher en bois, amiante gaufré et l'assemblage de mai- sons préfabriquées.1.35 Compagnon-menuisier en première année de pratique.1.20 Charretier.1.00 Chauffeur de camion.1.10 Chauffeur (construction).1.05 Chauffeur de bouilloire, devant posséder un certificat de 4ème classe.1.25 Conducteur de monte-charge.1.10 Conducteur de \"Bulldozer\".1.20 Conducteur de rouleau compresseur (vapeur ou essence).1.20 Conducteur de tracteur.1.20 Conducteur de niveleuse.1.20 Couvreur \u2014 ardoise, tuile.1.70 Couvreur \u2014 composition, gravier, sable, asphalte.1.35 Couvreur de plancher \u2014 linoléum, caoutchouc, asphalte ou équivalent (feuilles et tuiles).1.25 Aide couvreur de plancher.1.00 Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the construction industry in the city of St.John and the town of Iberville, rendered obligatory by the decree number 329 of February 20, 1947, have submitted to him a request to amend the said decree, as amended, as follows: 1.Section DII will be replaced by the following: \"in.Minimum wage rates: The following minimum rates of wages shall be paid: Hourly Trades rates Sprinkler fitter.$1.45 Bricklayer, plasterer (ordinary or ornamental work) mason, including cutter on the job, cement black layer, joint pointer.*.1.62 Caulkers.1.35 Carpenter, joiner, construction mechanic, including the following operations: concrete forms (shop of job), screen laying (wood or metal), frames, windows, weatherstrips, shingles (wood or asbestos or composition), steel partitions, furniture such as counters and shelves (fixed or moveable), any composition paper, including the laying of wood floors, corrugated asbestos and the as- sembling of prefabricated houses .1.35 Journeyman-joiner ,1st year.1.20 Horse driver.1.00 Truck driver.1.10 Fireman (construction).1.05 Boiler fireman with 4th class certificatse .1.25 Freight elevator operator.1.10 Bulldozer operator.1.20 Roller operator -steam or gasoline).1.20 Tractor operator.1.20 Grader operator.1.20 Roofer \u2014 slate, tile.1.70 Roofer \u2014 composition, gravel, sand, asphalt.1.35 Floor finisher \u2014 linoleum, rubber, asphalt or equivalent (sheet and tile).1.25 Floor finishing helper.1.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol.85, No.21 1737 Electricien-entrepreneurs, services personnels.2.50 Compagnon.1.50 Compagnon-électricien en première année de pratique.1.25 Finisseur de ciment .i^.1.45 Finisseur de plancher en mastic.1.40 Foreur et poudrier.1.35 Forgeron sur chantier.1.35 Gréeur.1.35 Gratteur, polisseur, sableur de plancher à la main ou à la machine.1.35 Homme de chaudière.1.00 Journalier (ouvrier non qualifié).1.00 Manœuvre, porteur d'oiseau.1.00 Limeur de scies.'.1.35 Machinistes.1.35 Mécanicien de machines fixes ou mobiles.1.30 Ouvrier-tôlier et ferblantier-couvreur (boutique ou chantier).1.50 Peintre, aspergeur, décorateur, vitrier, tapissier, vernisscur de plancher.1.35 Compagnon-peintre en première année de pratique.1.20 Plombier, poseur d'appareil de chauffage, mécanicien en tuyauterie: Entrepreneur \u2014 services personnels .2.50 Compagnon.1.50 Compagnon junior.1.35 Mécanicien en isolement de tuyauterie.1.50 Soudeur en tuyauterie (acétylène ou électricité).1.50 Poseur de brûleurs à l'huile.1.50 Pilonneur et épandeur d'asphalte.1.10 Porteur d'eau.1 \u2022 00 Préposé à la canalisation, moteur et soudeur.1.10 Poseur d'acier d'armature.1.45 Poseur de liège isolateur.1.50 Poseur de marbre.1.75 Poseur de plancher en mastic.1.60 Poseur de terrazzo.1.68 Poseur de tuiles.1.08 Poseur de lattes en bois ou en métal.1.35 Préposé au compresseur.1.30 Préposé aux grues.1.45 Préposé au malaxeur à vapeur ou au gros malaxeur à gazoline.1.45 Préposé au malaxeur à l'électricité ou au petit malaxeur à gazoline.1.05 Préposé aux bouilloires (travail de plancher seulement).1.30 Préposé aux machines à polir le terrazzo: machine à sec.1.53 machine à l'eau.1.35 Préposé aux pelles mécaniques.1 - 45 Gardien sur chantier (nuit et jour, sans limite de la durée quotidienne de travail, maximum hebdomadaire 72 heures).0.80 Surveillant, employé également comme chauffeur et devant posséder un certificat de 4ème classe (sans limite de la durée journalière de travail, maximum hebdomadaire 72 heures).1.30.¦par semaine Vérificateur de matériel et pointer.53.00 Lorsque du travail est exécuté par une équipe de nuit (2ème équipe), les salariés de cette équipe doivent recevoir un boni de $0.15 l'heure.\" 2° L'article IX sera remplacé par le suivant: \"IX.Le travail exécuté en dehors des heures régulières doit être rémunéré à temps et demi.Si le travail à exécuter se complète en moins d'une heure, l'ouvrier a droit au minimum d'une heure de travail.Le travail urgent, c'est-à-dire celui qui doit être exécuté pour éviter des dommages à la-personne et/ou à la propriété, peut être, fait Electrician: Contractor, personal services.2.50 Journeyman.1.50 Journeyman electrician, 1st year.1.25 Cement finisher.1.45 Mastic floor finisher.1.40 Drill operator and blaster.1.35 Blacksmith on the job.1.35 Rigger.1.35 Floor scraper and polisher, hand or machine .1.35 Kettleman.1.00 Labourer (common worker).1.00 Labourer, hod carrier.1.00 Saw setter.1.35 Machinist.1.35 Stationary or portable engineman.1.30 Tinsmith and sheet metal roofer (shop or job).1.50 Painter, sprayman, decorator, glazier, paper hanger, floor varnisher.1.35 Journeyman painter, 1st year.1.20 Plumber, steamfitter, pipe mechanic: Contractor, personal services.2.50 Journeyman.1.50 Junior journeyman.1.35 Pipe insulation mechanic.1.50 Pipe welder (acetylene or electricity) .1.50 Oil burner mechanic.1.50 Asphalt ramming and spreading.1.10 Water carrier.1.00 Piping, caulkers and welders.1.10 Reinforcing steel erector.1.45 Cork insulation layer.1.50 Marble layer.1.75 Mastic floor layer.1.60 Terrazzo layer.1.68 Tile layer.1.68 Lather, wood or metal.1.35 Compressor operator.1.30 Crane operator.1.45 Steam Leavy or gasoline mixer operator.1.45 Electric or light gasoline mixer operator.1.05 Kettleman, flooring only.1.30 Terrazzo polishing machine operator: dry process.1.53 wet process.1.35 Shovel operator.1.45 Watchman on the job (night and day, unlimited daily hours of work, weekly maximum of 72 hours).0.80 Watchman, also employed as fireman but with 4th class certificate (unlimited daily hours of work, weekly maximum of 72 .hours).1.30 per week ¦Material checker and time-keeper.53.00 When work is done by a night shift (2nd shift), the employees of such shift shall be paid a bonus of $0.15 per hour.\" 2.Section IX will be replaced by the following: \"IX.All time worked beyond the regular hours shall be paid at the rate of time and one half.If the work to be done is completed within one hour, the employee is entitled to a minimum of one hour's pay.Urgent work, meaning the work which must be executed to avoid damages to persons and/or properties, may be carried out outside the regular 1738 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 mai 1953, Tome 85, N° 21 en dehors des heures régulières et payé au taux régulier.La justification de cette urgence incombe à l'employeur.\" 3° Le paragraphe \"c\" de l'article VI sera remplacé par le suivant: c) Les préposés aux pelles et les préposés aux sonnettes (pile driver) de même que leurs compagnons de travail, les conducteurs d'attelage, les préposés au transport général, nu charroyage et au remorquage, vu la nature saisonnière de leur travail peuvent être employés sur une base maximum hebdomadaire de soixante (60) heures, sans limitation quotidienne de la durée de travail.Les taux pour le travail supplémentaire ne sont exigibles que pour le travail exécuté en plus de ce nombre d'heures.\" 4° Le paragraphe MkM de l'article XII sera remplacé par le suivant: \"k) Les taux de salaires suivants doivent être payés aux apprentis des métiers ci-après mentionnés: Taux horaire 1.Vharpenticr-racnuisier, peintre, asper-geur, vitrier, décorateur, tapissier et vernisseur: 1ère année.0.80 2ème aimée.0.90 3ème année.1.00 4ème année.1.05 2.Électricien, plombier, poseur d'appareils de chauffage, mécanicien en tuyauterie, soudeur en tuyauterie, ouvrier-tôlier et ferblantier-couvreur: 1ère année.0.S0 2ème année.0.90 Sème année.1.00 4ème année.1.05 3.Briqueteur, maçon, plâtrier: 1ère année.1.05 2ème année.1.10 3ème année.1.15 4ème année.1.30 4.Poseur de brûleurs à l'huile: 1ère année.0.90 2ème année.1.00 5.Couvreur de plancher linoléum, caoutchouc, asphalter ou équivalent (feuilles et tuiles) : 1ère année.0.85 2ème année.0.95 3ème année.1.05\" 5.L'article XII-A suivant sera ajouté: \"XLT-A.Outils: Les compagnons polmbicrs et les compagnons plombiers juniors doivent, dans les six mois qui suivent leur qualification, fournir un coffre muni d'outils pour le travail de tuyaux allant jusqu'à 2 pouces.Durant les trente jours à com *cr de la date de publication de cet avis dans la 'azeite officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 23 mai 1953.134889-0 hours and paid the regular rates.Justification # of the urgency shall lie with the employer.\" 3.Subsection \"c\" of section VI will be replaced by the following: \"c) Shovel operators and pile drivers, as well as their fellow-workers, horse drivers, general transport, cartage and haulage employees, due to the seasonal nature of their work, may be employed on a maximum weekly basis of sixty (00) hours, without daily limitation of the duration of labour.Overtime rates are payable only for work performed in excess of this number of hours.\" 4.Subsection \"&\" of section XII will be replaced by the following: \"k) The following minimum wage rates shall be paid to apprentices of the trades hereafter mentioned : Uourly rates 1.Carpenter-joiner, painter, sprinkler fitter, glazier, decorator, paper banger and varnisher: 1st year.$0.80 2nd year.0.90 3rd year.1.00 4th year.1.05 2.Electrician, plumber, steamfitter, pipe mechanic, pipe welder, sheet-metal worker and tinsmith-roofer: 1st year.0.80 2nd year.0.90 3rd year.1.00 4th year.1.05 3.Bricklayer, mason, plasterer: 1st year.1.05 2nd year.1.10 3rd year.1.15 4th year.1.30 4.Oil burner fitter: 1st year.0.90 2nd year.1.00 5.Floor Finisher, linoleum, rubber, asphalt or equivalent (sheet and tile): 1st year.0.85 2nd year.0.95 3rd year.1.05\" 5.The following section XII-A will be added: \"XII-A.Tools: Journeymen plumbers and junior journeymen plumbers shall, within the six months following their qualification, supply a chest with tools for pipe work up to two inches.During the thirty days following the date of gublication of this notice in the Quebec Official azette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested par-tics may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Department of Labour.Quebec, May 23,1953.34889-0 Avis d'approbation de règlements L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), que la constitution et les règlements généraux du \"Comité Notice of Approval of By-Laws The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), that the constitution and general by-laws of \"The Tanneries and Curriers QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1958, Vol 85, No.21 1739 Conjoint des Tanneries et Corroieries de la Province de Quebec\" établi en exécution du décret numéro 330 du 19 mars 1953, et dont le siège social est situé dans la cité de Québec, ont été approuvés par l'arrêté en conseil numéro 620-L du 20 mai 1953.v lie Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 23 mai 1953.34889-0 Avis d'approbation* de règlements L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), que la constitution et les règlements généraux du Comité conjoint de l'Industrie des Vêtements d'Hommes et de Garçons dans la province de Québec, établi en exécution du décret numéro 513 du 30 avril 1953, et dont le siège social est situé dans la cité de Montréal, ont été approuvés par l'arrêté en conseil numéro 614-D du 20 mai 1953.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 23 mai 1953.34889-0 AVIS L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention cllective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes ci-après mentionnées lui ont présenté une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: D'une part: La Boulangerie Racine Limitée: Et\", d'autre part: Le Syndicat National des Employés de la Boulangerie et Pâtisserie de Granby Inc.; pour les employeurs et les salariés de l'industrie et des métiers visés suivant les conditions ci-après décrites: I.Définitions: Pour les fins d'application du décret, les mots et termes suivants auront la signification qui leur est ci-après donnée: a) Le mot '\"employeur\" désigne toute personne, société, firme ou corporation qui contracte un louage d'ouvrage.b) Le mot \"salarié\" désigne tout apprenti, manœuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société.c) Le terme \"distributeur de pain, gâteaux et pâtisseries\" désigne le vendeur, solliciteur et percepteur qui est en charge d'une livraison de pain, de gâteaux et de pâtisseries, qu'elle soit faite en voiture à traction animale ou en camion ou de toute autre manière possible.d) les termes \"1er boulanger\" et \"1er pâtissier\" désignent un salarié affecté à la direction du personnel et de la production.e) le mot \"boulanger\" désigne un salarié qui possède les qualifications requises pour la fabrication du pain, des brioches ou tout autre produit à base de levure./) le mot \"pâtissier\" désigne un salarié qui possède les qualifications requises pour la pré- Joint Committee of the Province of Quebec\" establisheôfunder decree number 330 of March 19, 1953, with head office in the city of Quebec, have been approved by Order-in-Council number 620-L of May 20, 1953.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, May 23, 1953.34889-o Notice of approval of by-laws The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, Chapter 163 and amendments), that the constitution and * general by-laws of the Joint Committee of the Men's and Boys' Clothing Industry for the Province of Quebec, formed under Decree number 513 of April 30, 1953, with head office in the City of Montreal, have been approved by Order-in-Council number 614-D of May 20, 1953.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, May 23, 1953.34889-o NOTICE The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 103 and amendments), that the contracting parties hereafter mentioned have submitted to him a request to render obligatory the collective labour agreement entered into between: On the one part: \"La Boulangerie Racine Ltée\", And, on the other part: \"Le Syndicat national des Employés de la Boulangerie et Pâtisserie de Granby, inc.\", for the employer and the employees of the industry and the trades concerned according to the following conditions: I.Definitions: For the purposes of the decree, the following words have the meaning hereinafter given: o) The word \"employer\" means any individual partnership, firm or corporation who contracts for a hiring of work.b) The word \"employee\" means any apprentice, labourer or unqualified workman, qualified worker or journeyman, artisan, clerk or employee who works individually or with others or in partnership.c) The words \"bread, cake and pastry distributor\" means the seller, canvasser and collector who is in charge of the delivery of bread, cake and pastry, whether it be made with a horse drawn vehicle, a truck or any other way.d) The words \"head baker\" and \"head pastrycook\" mean an employee in charge of the person- \u2022 nel and production.e) The word \"baker\" means an employee with the competency required for the baking of bread, brioches or any other product made with yeast./) The word \"pastry-cook\" means an employee with the competency required for the prépara- 1740 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 mai 1963, Tome 85, N° 21 paration complète des gâteaux, des biscuits ou pâtisseries de toutes sortes.g) le terme \"homme de four\" désigne un salarié qui est affecté à la surveillance de la cuisson du pain et des pâtisseries de toutes sortes.h) Le terme \"pâtissier spécialisé\" désigne tout salarié spécialisé dans la fabrication de tous gâteaux de fantaisie, pièces montées ou glaçage de fantaisie.IL Juridiction: a) Juridiction territoriale: La juridiction territoriale du décret comprend la cité de Granby et le territoire compris dans un rayon de cinq (5) milles autour de ses limites.b) Juridiction industrielle: Sont assujettis aux dispositions du décret les employeurs, les employeurs professionnels, les artisans et les salariés de l'industrie et du commerce de la boulangerie et de la pâtisserie exerçant leurs activités dans la juridiction territoriale définie au paragraphe \"o\" du présent article.Les employeurs établis en dehors de la juridiction territoriale du présent décret sont cependant assujettis à .ses dispositions en ce qui concerne les salariés à leur emploi qui exercent leur travail en tout ou en partie dans ladite juridiction territoriale.III.Taux de salaires: a) Les taux minima de salaires suivants doivent être payés dans chacune des catégories ci-après mentionnées: Catégories: Salaires horaires Homme de pâte.$0.72 1er homme de four.0.71 Aide boulanger.'.0.71 Apprenti : 1ère année.,.0.51 2e année.0.56 3e année.0.61 par semaine tion of cakes, biscuits or pastries of all kinds.g) The words \"oven man\" mean an employee whose work is to check the baking of bread and pastries of all kinds.h) The words \"specialized pastry-cook\" means an employee specialized in the making of fancy cakes, icing, etc.II.Jurisdiction: a) Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction of the decree covers the town of Granby and the territory comprised in a radius of five (5) miles around its limits.b) Industrial jurisdiction: All employers, professional employers, artisans and employees of the baking and pastry-making industry and trades, operating within the territorial jurisdiction defined in subsection \"a\" of the present section, are governed by the provisions of the decree.Employers established outside the territorial jurisdiction of the present decree are however governed by its provisions as regards the employees in their employ doing their work, or part thereof, in the said territorial jurisdiction.III.Rates of wages: a) The following minimum rates of wages shall be paid in each of the categories hereinafter mentioned: Categories: Hourly rates Doughman.$ 0.72 Head oven man.-.0.71 Baker's helper.0.71 Apprentice: 1st year.0.51 2nd year.'.0.56 3rd year.0.61 per week Enveloppeur et contrôleur.$45.00 Wrapper and checker.$45.00 Salaires Garanti 52 semaines par semaine Pâtissiers.;.$45.00 de l'heure Aide pâtissier.$0.69 Apprenti : 1ère année.0.46 2e année.0.51 3e année.0.56 Employés féminins: 1ère année.0.46 2e année.'.0.51 3e année.0.56 Ouvrage général (homme).0.62 Vendeurs: Vente au détail.16H% Vente au gros.7 % par semaine Salaire garanti.' $40.00 l'heure Aide vendeur.0.70 b) Le salarié en charge d'une livraison de pain, de gâteaux et de pâtisseries, qu'elle soit faite en voiture à traction animale ou en camion ou de toute autre manière possible, est considéré comme premier homme sur cette voiture et doit retirer le salaire mentionné dans le présent article.c) Lorsqu'il y a deux (2) vendeurs sur le même véhicule, le salarié en charge de la livraison a la responsabilité et est considéré comme premier salarié, le deuxième salarié est considéré comme un aide et n'a droit qu'au salaire d'aide vendeur.52-week guarantee per week Pastry-cook.$45.00 Hourly Pastry-cook's helper.0.69 Apprentice : 1st year.0.46 2ne year.,- 0.51 3rd year.:.0.56 Female employees : 1st year.0.46 2nd year.0.51 3rd year.0.56 General band.0.62 Salesmen : > Retail.1GV2% Wholesale.7 % per week Guaranteed salary.$40.00 ¦Hourly Salesman's helper.$ 0.70 b) The employee in charge of the delivery of bread, cake and pastry, by horse-drawn vehicle, truck or otherwise, shall be considered as first man on that vehicle and shall be paid the wages mentioned in the present section.c) When there are two (2) salesmen on the same vehicle, the employee in charge of the delivery is held responsible and, in return, receives the higher wages; the second man is considered as a helper and receives the wages of the salesman's helper. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol 85, No.21 1741 d) Tout salarié remplaçant dans ses fonctions, d'une façon temporaire ou permanente, un autre salarié dont le salaire est supérieur, doit recevoir le salaire du salarié qu'il remplace.e) Pour ce qui a trait au salaire, l'employeur qui engage un nouveau salarié doit tenir compte de ses années d'apprentissage au service d'un autre employeur, comme boulanger, biscuiticr ou distributeur de pain ou patisserie sur présentation d'un certificat de l'ancien employeur.L'Employeur est tenu de fournir tel certificat à un salarié qui le quitte et le nouveau salarié est tenu de présenter ce certificat à son nouvel employeur./) Les salaires actuellement supérieurs à ceux stipulés dans le décret ne doivent pas être réduits au cours de l'existence dudit décret.IV.Durée du travail: a) La semaine régulière de travail pour tous les employés masculins sera de cinquante-cinq (55) heures et de cinquante (50) heures pour les employés féminins.b) Tout travail accompli en dehors des heures régulières sera considéré comme travail supplémentaire et rémunéré à raison de salaire et demi.Toutefois, si un salarié bénéficie d'un salaire supérieur au taux fixé par le décret, il doit recevoir pour son travail supplémentaire une rénumération égale au dit salaire supérieur majoré de 50%.V.Congé annuel payé: Après un (1) an de service pour son employeur, tout employé a droit à un congé annuel continu payé d'une durée minimum.de sept (7) jours fixé entre le 1er juin et le 1er novembre.Pour tout ce qui concerne les conditions relatives au congé annuel payé on doit référer aux dispositions de l'ordonnance no 3 revisée de la Commission du Salaire Minimum.Les employés ayant complété dix (10) ans de service le 1er mai précédent la période de vacances, auront droit à un congé annuel payé de deux (2) semaines, dont l'une sera prise dans la période comprise entre le 1er juin et le 1er novembre, et l'autre à la discrétion de l'Employeur.VI.Jours chômés et payés: a) L'employeur est tenu de faire chômer et de payer ses salariés les jours suivants: le Premier de l'An, le lendemain du Premier de l'An, l'Epiphanie, le Vendredi Saint, l'Ascension, la St-Jean-Baptiste, la Confédération, la Fête du Travail, la Toussaint, l'Imma-culée-Conception, Noël et le lendemain de Noël.b) Lorsque durant une semaine de travail, il y aura une journée chômée et payée, le temps supplémentaire pour cette semaine comptera à partir de soixante-cinq (65) heures pour les employés masculins et de cinquante-cinq (55) heures pour les employés féminins.VII.Dispositions spéciales: a) L'Employeur ayant moins de deux (2) salariés à son service n'a droit à aucun apprenti.L'employeur ayant deux (2) salariés ou plus à son service n'a droit qu'à un apprenti de chaque classe pour chaque catégorie de travail.b) Pour avoir droit de prendre le salaire du premier boulanger, pâtissier ou distributeur de pain, l'employeur doit travailler au moins quarante (40) heures par semaine dans sa boulangerie comme boulanger ou pâtissier, ou quarante (40) heures sur la voiture de livraison comme distributeur de pain.c) Les salariés doivent être payés chaque semaine dans des enveloppes fournies par l'employeur.ec Les Commissaires d'écoles pour la municipalité de rivière-ouelle (Comté de Kamouraska) Province of Quebec The School Commissioners for the Municipality of RlVlKRE-OuELLE (County of Kamouraska) Avis public est par les présentes donné que Public notice is hereby given that sealed des soumissions cachetées et endossées \"Sou- tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be missions pour obligations\" seront reçues par-le received by the undersigned Robert Richard, soussigné, Robert Richard, secrétaire-trésorier, Secretary-Treasurer, Rivière-Ouelle, county of Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska.jusqu'à Kamouraska, until 8 o'clock p.m., Thursday, 8 heures p.m.jeudi, le 11 juin 1953, pour l'achat June II, 1953, for the purchase of an issue of de 8180,000 d'obligations des commissaires 8180,000.00 of bonds of the School Commissioners d'écoles pour la municipalité de Rivière-Ouelle, for the Municipality of Rivière-Ouelle, county Cté Kamouraska, datées du 1er juin 1953 et of Kamouraska, dated June 1st, 1953, and redee- remboursables par séries du 1er juin 1954 au mable serially from June 1st, 1954 to June 1st 1er juin 1973 inclusivement, avec intérêt à un 1973 inclusively, with interest at a rate not less taux nop.inférieur à 3% ni supérieur à 4|^% than 3% and not more than 4^2% per annum, par année payable semi-annuellement les 1er payable semi-annually on June 1st and December juin et 1er décembre de chaque année.Le taux 1st, of each year.The rate of interest may be d'intérêt peut être le même pour toute l'mission the same for thte whole issue or it may vary ou il peut varier suivant les échéances.Le according to maturities.The table of redemp- tableau d'amortissement est le suivant: tion is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 $180.000.00\u201420 ans Année Capital lei juin 1954.: x$23,500.00 1er juin 1955.x 24,500.00 1er juin 1956.x 25,500.00 1er juin 1957.x 27,000.00 1er juin 1958.x 28,000.00 1er juin 1959.2.500.00 Table of redemption \u2014 $180.000.00 \u2014 20 years Year Capital June 1st, 1954.x$23,500.00 June 1st, 1955.x 24,500.00 June 1st, 1956.x 25,500.00 June 1st, 1957.x 27,000.00 June 1st, 1958.x 28,000.00 June 1st, 1959.2,500.00 1758 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 mai 1958, Tome 86, N° 21 1er juin 1000.- 2,500.00 1er juin 1961.2,500.00 1er juin 1962.3,000.00 Ici juin 1963 .3,000.00 1er juin 1901.3,000.00 1er juin 1905.3.000.00 1er juin 1900.'.3.500.00 1er juin 1907.3,500.00 lei juin 1908.3.500.00 1er juin 1909.4.000.00 1er juin 1970.4.000.00 1er juin 1971.4.500.00 1er juin 1972.4,500.00 1er juin 1973.4,500.00 Ix's x indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $133,-850, accordé par le Secrétaire de la province et payable en cinq versements de $26,770 chacun, de 1954 à 1958 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Rivière-Ouelle.Cté Kamouraska.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, n Québec, à Stc-Anne-Anne-de-la-Pocatière on à Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant île l'cmpiunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue jeudi, le 11 juin 1953.à 8 heures p.m., à l'École N° 1 de Rivière-Ouelle.comté de Kamouraska.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Rivière-Ouelle, (Comté de Kamouraska), ce 21 mai 1953.Le Secrétaire-trésorier, ROBERT RICHARD.Rivière-Ouelle, (Comté de Kamouraska), P.Q.34902-o June 1st, June 1st, June 1st, June 1st, June 1st, June 1st.June 1st, June 1st, June 1st, June 1st, June 1st, June 1st, June 1st.' June 1st.1900.1901.1902.1903.1904.1905.1900.1907.1908.1909.1970.1971.1972.1973.2,500.00 2,500.00 3.000.00 3,000 00 3,000.00 3.000.00 3,500.00 3,500.00 3.500.00 4.000.00 4,000.00 4.500.00 4,500.00 4.500.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $133.850.granted by the Provincial Secretary and payable in five instalments of 820.770 each, from 1954 to 1958 inclusively, will be received and applied to the service of this loan r.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Rivière-Ouelle, county of Kamouraska.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec, Ste-Anne-de-la-Pocatière or Rivière-Ouelle, county of Kamouraska.The said bonds are.under the authority of Chapter 212.Revised Statutes of Quebec 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par.at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a cprtified cheque equal to 1 % of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Thursday the 11th day of the month of June 1953.at 8 o'clock p.m., at School Xo 1 of Rivière-Ouelle, county of Kamouraska.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Rivière-Ouelle, (County of Kamouraska), this May 21 st, 1953.ROBERT RICHARD, Secretary-Treasurer.Rivière-Ouelle, (County of Kamouraska), P.Q.34902 Province de Québec Ville Saint-Laurent Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Lucien Toupïn, greffier et gérant, 14 rue de l'Égl'se, Ville Saint-Laurent, jusqu'à 8 heures p.m., vendredi, le 12 juin 1953.pour l'achat de $845,000 d'obligations de Ville Saint-Laurent, datées du 1er juin 1953 et remboursables par séries du 1er juin 1954 au 1er juin 1973 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4]A% par année payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Province of Quebec Town of Saint-Laurent Public notice is hereby given that tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Lucien Toupin, clerk and manager, 14 Church Street, Town of Saint-Laurent, until 8 o'clock p.m.Friday, June 12, 1953, for the purchase of an issue of $845,000 of bonds of the Town of Saint-Laurent, dated June 1st, 1953 and redeemable serially from June 1st, 1954 to June 1st.1973 inclusively, -with interest at a rate not less than 3% more more than 43^ per annum, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1053, Vol.86, No.21 1759 Tableau d'amortissement \u2014 $81)6,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1954 .§27,000.00 1er juin 1955 .29,000.00 le.juin 195G.29,000.00 1er juin 1957.30,000.00 1er juin 1958 .33,000.00 1er juin 1959 .31,000.00 1er juin 1900.35,000.00 1er juin 1901 .30,000.00 1er juin 1902 .39,000.00 1er juin 1903 .40,000.00 1er juin 1904 .42.0(H).00 1er juin 1905 .43,000.00 1er juin 1906 .40.000.00 1er juin 1907 .48,000.00 1er juin 1908 .50,000.00 1er juin 1909 .52,000.00 1er juin 1970 .54,000.00 1er juin 1971 .57,000.00 1er juin 1972 .59,000.00 1er juin 1973 .62,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Ville Saint-Laurent.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec ou à Ville Saint-Laurent.Lesditcs obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue vendredi, le 12 juin 1953.à 8 heures p.m.dans la salle de l'École Beaudet, 209 Boulevard Décarie, Ville Saint-Laurent.Le consc:l se réserve le droit de n'accepter ni la phis haute ni aucune fies soumissions.Vi'le Saint-Laurent, ce 8 mai 1953.Le Greffier et gérant, LUCIEN TOUPIN, 14 rue de l'Église, Ville Saint-Laurent, P.Q.34860-o Province de Québec Ville de Charlesbourg (Comté de Québec) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le sous-signe, J.-M.Darveau, secrétaire-trésorier, 5, 45 ème rue ouest, B.P.105, Charlesbourg, comté de Québec, jusqu'à 8 heures p.m., lundi, le 8 juin 1953, pour l'achat de 893,000.00 d'obligations de la ville de Charlesbourg, comté de Québec, datées du 1er juin 1953 et remboursables par séries du 1er juin 1954 au 1er juin 1973 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 43^% par année payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux «l'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Table of redemption \u2014 $845,000 \u2014- 20 years Year Capital .June 1st, 1954.827,000.00 June 1st, 1955.29,000.00 June 1st, 1950.29,000.00 June 1st, 1957 .30,000.00 June 1st, 1958.33,000.00 June 1st, 1959.34,000.00 June 1st, 1900.35,000.00 June 1st, 1901.36,000-00 June 1st, 1962.39,000.00 June 1st, 1903 .40,000.00 June 1st, 1964 .42,000.00 June 1st, 1965.43,000.00 June 1st, 1966.46,000.00 June 1st, 1907.48,000.00 June 1st, 1908.50,000.00 June 1st, 1909.52,000.00 June 1st, 1970.54,000.00 June 1st, 1971.57,000.00 June 1st, 1972.59,000.00 June 1st, 1973.- 62,000.00 The successful temlerer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interests, if any, by certified cheque payable at par at the Town of Saint-Laurent.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at the Town of Saint-Laurent.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941 subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity «late; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount-of the present issue ami must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Friday June 12, 1953, at 8 o'clock p.m., in the Beaudct School Hall, 209 Décarie Boulevard.Town of Saint-Laurent.The Council «locs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Town of Saint-Laurent.May 8, 1953.LUCIEN TOUPIN, Clerk and Manager.14 Church Street, Town of Saint-Laurent.P.Q.34860 Province of Quebec Town ok Charlesbourg (County of Quebec) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be recciv-e«l by the undersigns! J.M.Darveau, Secretary-Treasurer, 5, 45th Street, West, P.O.B.105, Charlesbourg, County Quebec, until 8 o'clock p.m., Monday, June 8,1953, for the purchase of an issue of 893,000.00 of bonds of the town of Charlesbourg County of Quebec dated June 1st, 1953 and redeemable serially from June 1st 1954 to to June 1st, 1973 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor more than 4^% Per annum, payable semi-annually on June 1st an«l December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: 1760 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 mai 1968, Tome 86, N° 21 Tableau d'amortissement \u2014 $93,000.00 \u2014 20 ans.Année Capital 1er juin 1954.$3,000.00 1er juin 1955.3,000.00 1er juin 1956 .3,000.00 1er juin 1957.3,500.00 1er juin 1958 .3,500.00 1er juin 1959.3,500.00 1er juin 1960.4,000.00 1er juin 1961.4,000.00 1er juin 1962.4,000.00 1er juin 1963 .4,500.00 1er juin 1964.4,500.00 1er juin 1965 .5,000.00 1er juin 1966 .5,000.00 1er juin 1967 .5,500.00 1er juin 1968.5,500.00 1er juin 1969.5,500.00 1er juin 1970 .6,000.00 1er juin 1971.6,500.00 1er juin 1972.6,500.00 1er juin 1973.7,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y u lieu, par chèque visé, payable au pair à Charlesbourg, comté de Québec.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec ou à Charlesbourg, comté de Québec.Lesditcs obligations pourront, sous ''autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment rie leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 8 juin 1953, à 8 heures p.m.au lieu ordinaire des séances, en la salle paroissiale de Charlesbourg.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Charlesbourg, (Comté de Québec), ce 19 mai 1953.Le Secrétaire-trésorier, J.-M.DARVEAU, 5, 45ème rue ouest, B.P.105, Charlesbourg, (Québec), P.Q.34878-o Table of redemption \u2014 $98,000.00 \u2014 20 years.Vear Capital June 1st, 1954.$3,000.00 June 1st, 1955.3,000.00 June 1st.1956.3,000.00 June 1st, 1957.3,500.00 June 1st, 1958.3,500.00 June 1st, 1959.3,500.00 June 1st, 1960.4,000.00 June 1st, 1961.4,000.00 June 1st, 1962.4,000.00 June 1st, 1963.4,500.00 June 1st, 1964.4,500.00 June 1st, 1965.5,000.00 June 1st, 1966.5,000.00 June 1st, 1967.5,500.00 June 1st, 1968.5,500.00 June 1st, 1969.5,500.00 June 1st, 1970.6,000.00 June 1st, 1971.6,500.00 June 1st, 1972.6,500.00 June 1st, 1973.7.000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Charlesbourg, County of Quebec.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure, at Montreal, Quebec or at Charlesbourg, county of Quebec.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held Monday June 8, 1953, at 8 o'clock p.m., at the ordinary meeting place, in the parochial hall of Charlesbourg.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Charlesbourg, (County of Quebec) May 19, 1953.J.M.DARVEAU, Secretary-Treasurer, 5, 45th Street West, P.O.B.105, Charlesbourg, (Quebec), P.Q.34878 Province de Québec Cité de St-Lambert (Comté de Chambly) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, C.F.Potter, Secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, St-Lambert, comté de Chambly, jusqu'à 8 heures p.m., lundi, le 8 juin 1953, pour l'achat de $155,000 d'obligations de la cité de St-Lambert, comté de Chambly, datées du 1er juillet 1953 et remboursables par séries du 1er juillet 1954 au 1er juillet 1973 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4^% par année payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant Province of Quebec City of St.Lambert (County of Chambly) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned C.F.Potter, Secretary-Treasurer, City Hall, City of St.Lambert, County of Chambly, until 8 o'clock p.m., Monday, June 8th, 1953, for the purchase of an issue of $155,000 of bonds of the City of St.Lambert, County of Chambly, dated July 1st, 1953, and redeemable serially from July 1st, 1954 to July 1st, 1973 inclusively, with interest at a rate that shall not be less than 3% nor more than 43^% per annum, payable semi-annually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol 85, No.21 1761 les échéances, le suivant: Le tableau d'amortissement est The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 $155,000.00 \u2014 20 ans Année v Capital 1er juillet 1954.$5,000.00 1er juillet 1955.5,000.00 1er juillet 1956.5,500.00 1er juillet 1957.5,500.00 1er juillet 1958.5,500.00 1er juillet 1959.6,000.00 1er juillet 1960.6,000.00 1er juillet 1961.6,500.00 1er juillet J962.7,000.00 1er juillet 1963.7,500.00 1er juillet 1964.8,000.00 1er juillet 1965.8,000.00 1er juillet 1966.8,500.00 1er jui'lct 1967.9,000.00 1er juillet 1968.9,000.00 1er juillet 1969.9,500.00 1er juillet 1970.10,000.00 1er juillet 1971.10,500.00 1er juillet 1972.11,000.00 1er juillet 1973.12,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Lambert, Cté Chambly.Le capital et les intérêts sont payable à toutes les succursales d'une banque à charte dans la province de Québec ou clans la cité de Toronto, où à une autre banque à charte dans la cité de Toronto.Lesditcs obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts lté fondus de Québec 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi le 8 juin 1953, à 8 beures p.m., en l'Hôtel de Ville de St-Lambert, comté de Chambly.Le sonseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Lambert, (Comté de Chambly), ce 13 mai 1953.Le Secrétaire-trésorier, C.F.POTTER.Hôtel de Ville, St-Lambert, (Cté Chambly) P.Q.34859-o Table of redemption \u2014 $155,000.00 \u2014 20 years Year Capital July 1st, 1954.5,000.00 July 1st, 1955.5,000.00 July 1st, 1956.5,500.00 July 1st, 1957.5,500.00 July 1st, 1958.5,500.00 July 1st, 1959.6,000.00 July 1st, I960.6,000.00 July 1st, 1961.6,500.00 July 1st, 1962.7,000.00 July 1st, 1963.7,500.00 July 1st, 1964.8,000500 July 1st, 1965.8,000.00 July 1st, 1966.8,500.00 July 1st, 1967.9,000.00 July 1st, 1968.9,000.00 July 1st, 1969.9,500.00 July 1st, 1970.10,000.00 July 1st, 1971.10,500.00 July 1st, 1972.11,000.00 July 1st, 1973.12,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bons, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at St.Lambert, Co.Chambly.Capital and interest are payable at all branches of a chartered bank in the Province of Quebec or in the City of Toronto, or at another chartered bank in the City of Toronto.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serail number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Monday, June 8th, 1953 at 8 o'clock p.m., at thet'City Hall of St.Lambert, County of Chambly.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St.Lambert, (County of Chambly), this 13th of May, 1953.C.F.POTTER, Secretary-Treasurer.City Hall, St.Lambert, (Co.Chambly), P.Q.34859-0 Ventes pour taxes Province de Québec, district de Chicoutimi Commission Scolaire de Canton Taché Sales for Taxes Province of Quebec, District of Chicoutimi School Commission of the Township of Taché Avis public est, par les présentes donné que la Public notice is hereby given that the Quebec Commission municipale de Québec, par un arrêté Municipal Commission by an Order dated may en date du neuf mai 1953, a ordonné au soussigné, ninth 1953, has ordered the under signed, pursu-conformément aux dispositions de l'article 54 ant to the provisions of section 54 of the Quebec de la Loi de la Commission municipale de Québec Municipal Commission Act, (R.S.Q.1941, chapter (S.R.Q.1941, chapitre 207) de vendre l'immeuble 207) to sell the immoveable hereinunder desi-ci-dessous désigné, pour satisfaire au paiement gnated, in payment for arrears of taxes due to desjarrérages de taxes dues aux commissaires the School Commissioners for the municipality 1762 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Quebec, 23 mai 1953, Tome 85, N° 21 d'écoles pour la municipalité de canton Taché et à la corporation'municipale de canton Taché (St-Nazaire) avec intérêts et frais, et qu'en conséquence', ledit immeuble sera vendu par encan pub'ic, dans la salle publique de canton Taché (St-Nazaire), le DIX-SEPT JUIN 1953, a ONZE heures de Pavant-midi, heure avancée.Toutefois, ledit immeuble sera exclus de la vente si les taxes scolaires échues le ou avant le 30 juin 1953 sont payées, avec les frais, avant le moment de la vente.1.Joseph-Henri Martel.Le lot 21, rang 8, au cadastre oflieiel du canton Taché, sous billet de location, avec réserve des droits de la compagnie Electrique du Saguenay pour un passage de ligne de transmission d'énergie électrique, suivant acte dûment enregistré.Le dit lot sera vendu avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes pouvant l'affecter.Les versements non échus des taxes municipales ou scolaires consolidées, s'il en est, seront à la charge de l'acquéreur.Le prix d'adjudication de cet immeuble sera payable immédiatement.La vente sera en outre sujette au droit de retrait et aux autres dispositions de la Loi de la Commission municipale de Québec.Donné à Saint-Nazaire, ce 1 Lième jour du mois de mai 1953.Le Secrétaire-trésorier, 34868-2 l-2-o J.A.TREMBLAY.Province de Québec Cite de Noranda Avis public est par les présentes donné que conformément à une résolution du conseil en date du 24 avril 1953, le secrétaire-trésorier de la cité de Noranda vendra à l'enchère le QUINZIÈME jour de JUIN 1953, à DIX heures de l'avant-midi, au bureau du conseil.Bâtisse Municipale, 321 avenue Murdoch, Noranda, P.Q.de la manière prescrite par la loi, les immeubles suivants sur lesquels les taxes municipales et scolaires n'ont pas été payées: of the Township of Taché and to the municipal corporation of Taché Township (St-Na/aire) with interests ami costs, and that consequently, the said immoveable shall be sold at public auction in the public hall of Taché Township (St-Nazaire), JUNE SEVENTEENTH 1953.at ELEVEN o'clock in the forenoon, daylight saving time.However, the said immoveable shall be excluded from the sale if the school taxes overdue'on or after June 30th\\ 1953, are paid plus costs, before the time of the sale.1.Joseph Henri Martel \u2014 Lot 21, range S, of the official cadastre of Township Taché under location ticket, with reserve of rights of \"La Compagnie Electrique du Saguenay\" to p iss an electric power transmission line, in accordance with a duly registered deed.The said lot shall be sold with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, and with all active and passive servitudes, apparent or unapparent by which it may be affected.The unmatured instalments of consolidated municipal or school taxes, if any, shall be charged to the purchaser.The adjudication price of said immoveable shall be payable immediately.Moreover, the sale shall be subject to right of redemption and to other provisions of the Quebec Municipal Commission Act.Given at St-Nazaire, this Uth dav of the month of May 1953.J.A.TREMBLAY.34808-21 -2 Secretary'Treasurer.Province of Quebec City of Noranda Public notice is hereby given that pursuant to a resolution of the Council made on April 24th 1953, the secretary-treasurer of the city of Noranda will on the FIFTEENTH day of JUNE, 1953.at TEN o'clock in the forenoon at the office of the Council Municipal Building, 321 Murdoch Ave Noranda, P.Q., sell at public auction in the manner prescribed by law the following immoveables on which the municipal and school taxes assessed have not been paid: Description des Propriétés Description of property\tNoms des propriétaires Name of owners\tTaxes non-payees Unpaid taxes Le lot N° 370 (trois cent soixante-dix) du cadastre officiel de.la cité de Noranda.\u2014 Lot No.370 (three hundred and seventy) of the official cadastre of the City of Noranda.Bâtisses seulement, construites sur partie de terrain non subdivisé do Noranda Mines Ltd., et situées dans le Bloc 1 (un) de la cité de Noranda.Buildings only, erected on part of unsubdivided ground of Noranda Mines Ltd.and located in Block 1 (one) of the City of Noranda.\tDaniel Angeloff, Evan Angeloff.\tSI 89.52 194.81 \t\t \t\t \t\t Donné à Noranda, ce 15e jour de mai, 1953.Given at Noranda, this 15th day of May, 1953 Le Secrétaire-trésorier, C.-E.COMEAU, 34870-21-2-o C.-E.COMEAU.34870-2l-2-o Secretary-treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May SSrd, 195S, Vol.86, No.U 1703 Province de Québec VïLLE DE BELOEIX Avis public est par le présent donné par le soussigné, secrétaire-trt?sorier de la ville de Be-lceil, que conformément à une résolution du conseil en date du 4 mai, 1953, les immeubles ci-dessous mentionnés seront vendus à l'enchère publique, au bureau du conseil, à l'Hôtel de Ville, MARDI, le NEUF JUIN prochain (1953), à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires mentionnées dans l'état ci-dessous et des frais qui seront encourus, à moins que les dites taxes et frais ne soient plus tôt payés.Province of Quebec Town of Beloeil Public notice is hereby given by the undersigned, secretary-treasurer of the town of Beloeil, that pursuant to an order of the Council made on May 4, 1953, the immoveables hereinafter described will be sold by public auction in the office of the Town's Council, at the city Hall, on TUESDAY, the NINTH dav of the month of JUNE next (1953), at TEN o'clock in the forenoon, for the non payment of the municipal and school taxes hereunder mentioned and the costs which shall be incurred unless the said taxes and costs be paid before the sale.Nom Nam*\tDescriptions des propriétés Description of property\tTaxes Munie.Munie.Taxes\tGaxos Scol.School taxes \tSubdivisions 50 ot 51 du cadastre originaire 36, aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse St-Mathieu do Belœil \u2014 Subdivisions 50 and 51 lof original cadastre 30 on the Official Plan and Book of Reference of the parish St.Ma-\ttil.02\t$22.84 \t\t\t \t\t\t Donné à Beloeil, ce 8ième jour de mai 1953.Le Secrétaire-trésorier, 34829-20-2-O P.R.CHOQUETTE.Given at Belœil, this 8th day of May 1953.P.R.CHOQUETTE, 34829-20-2-O Secretary-Treasurer.Prévint» *\u2022 Qntk\u2014 IlEB-DE-LA-MaDBLEINE Avis public est par le présent donné par le soussigné, F.A.Painchaud, Secrétaire-Trésorier du Conseil de Comté des Bcs-de-la-Madeleine, que les immeubles ci-dessous mentionnés, seront vendus à l'enchère publique, au Palais de Justice de Havre-Aubert, MERCREDI, le HUITIÈME jour de JUILLET 1953, à DIX heures de l'avant-midi pour taxes municipales et scolaires dues sur ces immeubles à moins qu'elles ne soient payées avant la vente, savoir: Dans la municipalité de Havre-Aubert Est Comme appartenant à Suce.Octave Briand, ou semblant lui appartenir, un lot se terre connu et désigné au cadastre de l'Ile Amherst, dans les Res-de-la-Madeleirie, sous la subdivision 133 du lot N° 143-F, contenant 14-0-0 en superficie.Taxe municipale: $1.36- taxe scolaire: $4.08.Dans la municipalité de Havre-Aubert Comme appartenant à Suce.Chrystophc Vigneau et étant occupé par Grégoire J.Lapierre, un lot de terre connu au môme cadastre sous le numéro 171, contenant 1-0-0 en superficie.Taxe municipale $0.91; taxe scolaire: $2.40.dans la MUNicrpAUTé db Grande Entrée Comme appartenant à Suce.Enerie Lapierre, un lot de terre connu au cadastre de Coffin Province of Quebec Magdalen Islands Public notice is hereby given by the undersigned F.A.Painchaud, Secretary-Treasurer of the County Council of Magdalen Islands, that the immoveables hereafter mentioned will be sold by public auction, at the Court House at Havre-Aubert, on WEDNESDAY, the EIGHTH day of JULY 1953, at TEN o'clock in the forenoon, for municipal and school taxes due upon these immoveables, unless the same be paid with cost before the sale, to wit: In the Municipality of Havre-Aubert-East As belonging to Est.Octave Briand or supposed to belong to him, one lot of land known and described on the official cadastre of Amherst, in the Magdalen Islands, under the subdivision 133 of the lot N° 143-F, containing 14-0-0 in area.Municipal taxe: $1.36; School taxe: $4.08.In the Municipality of Havre-Aubert As belonging to Est.Chrystophe Vigneau and being occupied by Grégoire J.Lapierre, one lot of land known on the same cadastre under the number 171, containing 1 -0-0 in area.Municipal taxe: $0.91; School taxe: $2.40.In the Municipality of Grande Entrée As belonging to Est.Enerie Lapierre, one lot on land known on the cadastre of Coffin Island, 1764 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S3 mai 1953, Tome 85, N 21 Island, dans les Ues-de-la-Madeleine, sous la subdivision 170 du lot No.52, contenant 11-1-0.Taxe municipale: 84.70- taxe scolaire: 821.50.Dans la Municipalité de Havres-aux-Maisons Comme appartenant à Suce.Béloni Tubide et étant occupé par Eugène Turbide, un lot de terre connu au cadastre de l'Ile Alright sous la subdivision 84 du lot N° 73 contenant 7-2-0 en superficie avec bâtisses dessus construites.Taxe municipale: $2.75- Taxe scolaire: $18.70.Comme appartenant à Elso Poirier, quatre lots de terre connus au même cadastre comme lot 79 contenant 6-0-20, lo t78 contenant 4-1-2, subdivision 179 du lot No.75 contenant 7-1-16 et N° 140 contenant 5-0-0 avec bâtisses dessus construites.Taxe municipale: $11.34- Taxe scolaire: $47.67.Comme appartenant à Chrystophe Poirier ou semblant lui appartenir, neuf lots de terre connus au même cadastre, comme suit: Subdivision 391 du lot N° 139 contenant 3-2»36- Subd.95 du lot N° 75 contenant 5-0-0-Subd.439 du lot 73 contenant 0-3-0- Subd.180 du lot 73 contenant 0-3-0- Subd.180 du lot N°73 contenant 4-2-0- Subd.181 du lot N° 75 conte-tenant 9-0-0- Partie du lot 73 contenant 4-2-0-Partie du lot 139 contenant 1-3-0- Partie du lot 141 contenant 3-1-0 et subdivision 95 du lot N° 75 contenant 5-0-0, avec bâtisses dessus construites.Taxe municipale: $12.85.- Taxe scolaire: $73.78.Dans la Municipalité de l'Étano-du-Nord Comme appartenant à Succession Isidore R.LeBlanc, un lot de terre connu au cadastre de l'Ile Grindstone, sous la subdivision 757 du lot N° 214 contenant 12-1-12.Taxe municipale: $6.02- Taxe scolaire: $89.87.Comme appartenant à François M.LeBlanc, un lot de terre connu au même cadastre sous le numéro 247 contenant 5-3-0 avec bâtisses dessus construites.Taxe municipale: $0.59- Taxe scolaire: $23.07.Comme appartenant à Suce.François Massé, un lot de terre connu au même cadastre comme faisant partie du lot N° 123 contenant 5-0-0 avec bâtisses dessus construites.Taxe municipale: $5.11- Taxe scolaire: $43.28.Comme appartenant à Suce.Ernest Poirier, un lot de terre connu au même cadastre comme sub.658 du lot N° 259 contenant trois acres en superficie.Taxe municipale: $0.74- Taxe scolaire: $4.41.Comme appartenant à Euclide Bourque & al.deux lots de terre connus au même cadastre comme partie de subdivision 489 du lot N° 71, contenant 7-0-0 et subdivision 514 du lot N° 214 contenant 5-3-0, avec bâtisses dessus construites.Taxes municipale: $3.34- Taxe scolaire: $10.80.Comme appartenant à Hypolite L.Richard, deux lots de terre connus au même cadastre comme formant partie du lot N° 284-A contenant 0-2-35 et partie du lot N° 286 contenant 1-3-0 avec bâtisses dessus construites.Taxe municipale: $0.54- Taxe scolaire: $3.60.Donné à Havre-Aubert, I.M.ce septième jour de mai 1953.Le Secrétaire-Trésorier du Conseil de Comté des Ues-de-la-Madeleine, 34830-20-2-0 F.A.PAINCHAUD.in the Magdalen Islands under the subdivision 170 of the lot N° 52, containing 11-1-0.Municipal taxes: $4.70; School taxes: $21.50.In the Municipality of Havres-aux-Maisons As belonging to Est.Beloni Turbide and being occupied by Eugène Turbide, one lot of land known on the cadastre of Alright Island, under the subdivision 84 of the lot No.73 containing 7-2-0 in area with buildings thereon erected.Municipal taxe: $2.75; School taxe: $18.70.As belonging to Elso Poirier, four lots of land known on the same cadastre as lot 79 containing 6-0-20, lot 78 containing 4-1-2, subdivision 179 of the lot No.75 containing 7-1-16 and No.140 containing 5-0-0 with biuldings thereon erected.Municipal taxes: $11.34; School taxes: $47.67.As belonging to Chrystophe Poirier or supposed to belong-fcojjim, nine lots of land known on the same cadastre as follows: Subdivision 391 of the lot No.139 containing 3-2-36, Subd.95 of the lot No.75 containing 5-0-0; Subdivision 439 of the lot No.73 containing 0-3-0; Subdivision 180 of the lot No.73 containing 4-2-0, Subdivision 181 of the lot No.75 containing 9-0-0; Part of the lot No.73 containing 4-2-0; Part of the lot No.139 containing 1-3-0; Part of the lot No.141 containing 3-1-0 and subdivision 95 of the lot No.75 containing 5-0-0 with buildings thereon erected.Municipal taxe: $12.85; School taxe:$73.78.In the Municipality of Etanq-du-Nord As belonging to Estate Isidore R.LeBlanc, one lot of land known on the cadastre of Grindstone, Island, under the subdivision 757 of the lot No.214 containing 12-1-12.Municipal taxe: $6.02; School taxe: $89.87.As belonging to François M.LeBlanc one lot of land known on the same cadastre under the number 247 containing 5-3-0, with buildings thereon erected.Municipal taxe: $0.59; School taxe: $23.07.As belonging to Estate François Massé one lot of land known on the same cadastre as forming part of the lot No.123 containing 5-0-0 with buildings thereon erected.Municipal taxe; $5.11; School taxe: $43.28.As belonging to Estate Ernest Poirier, one lot of land known on the same cadastre as subd.658 of the lot No.259, containing three acres in area.Municipal taxe: $0.74; School taxe: $4.41.As belonging to Euclide Bourque & al.two lots of land known on the same cadastre as part of subdivision 489 of the lot No.71, containing 7-0-0 and subdivision 514 of the lot No.214 containing 5-3-0 with buildings thereon erected.Municipal taxe: $3.34; School taxe: $10.80.As belonging to Hypolite Richard, two lots of land known on the same cadastre as forming part of lot No.284-A containing 0-2-35 and part of lot No.286 containing 1-3-0 with buildings thereon erected.Municipal taxe: $0.54- School taxe: $3.60.Given at Havre-Aubert, M.I.this seventh day of May, 1953.F.A.PAINCHAUD, Secretary-Treasurer of the County 348S0-20-2-O Council of the Magdalen Islands. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol 85, No.21 1765 VENTES PAR SHÊRLFS AVIS PUBLIC, est par le présent donné que lea TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.ABITIBI Province de Québec, District d'Abitibi Cour de Magistrat, / \\ KAURICE LEVES-N° 12,583.< iVl QUE, épicier faisant l affaire et étant domicilié à Rochebeaucourt, district d'Abitibi, demandeur, vs JOSEPH LANCTOT, domicilié à Rochebeaucourt, district d'Abitibi, défendeur.AVIS DE VENTE Les droits acquis sur le lot numéro 17 rang 6, du Canton Rochebeaucourt avec bûtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de Rochebeaucourt le SAMEDI VINGT-SEFr JUIN 1953 à TROIS heures de l'après-midi, (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, FERDINAND GERVAIS.Amos le 19 mai 1953.34883-21-2-0 BEAUHARNOIS Fieri Faicas de Terris Canada, Province de Québec District de Beauharnois.Cour Supérieure, / T ^OFFICE DU CRÉDIT N° 1041.< JLv AGRICOLE DU QUÉ-i BEC, corps politique et incorporé ayant son siège social à Québec, district de Québec, requérant, ys NELSON BASKIN, de Hemmingford, district de Beauharnois, R.R.No.-3, comté de Huntingdon, Intimé.Saisie comme appartenant au dit intimé: Une terre sise et située dans le canton de Hemmingford, comté de Huntingdon, connue et désignée aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Hemmingford comme étant le lot numéro cinquante-cinq A (N° 55A) du deuxième rang des terrains octroyés, contenant cent-six acres et vingt perches en superficie, moins, cependant, une petite lisière de terrain mesurant soixante pieds par cent-douze pieds détachée du coin sud-ouest dudit lot et étant un cimetière privé.Avec les bâtisses dessus érigées.Pour être vendue à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de St.Romain de Hemmingford, comté de Huntingdon, district de Beauharnois, VENDREDI, le CINQ JUIN 1953, à DIX heures de l'avant-midi (heure avancée) Le Shérif, Bureau du Shérif, HORACE VIAU.Valleyfield, le 27 avril 1953 34744-18-2 BONA VENTURE Canada, Province de Québec, District de Bonaventure New Carlisle.Cour Supérieure, / X-TECTOR LAFERTÉ, de la N° C684.< A J- cité de Québec, district Ide Québec, demandeur, vs SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI Province of Quebec, District of Abitibi Magistrate's Court, ( \\ KAURICE LEVES-No.12,583.\\ AVJ.QUE, grocer doing I business and being domiciled at Rochebeaucourt, District of Abitibi, plaintiff, vs, JOSEPH LANCTOT, domiciled at Rochebeaucourt, District of Abitibi, defendant.NOTICE OF SALE The rights acquired on lot number 17, range 6, of the Township of Rochebeaucourt, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies., To be sold at the parochial church door of Rochebeaucourt, SATURDAY, JUNE TWENTY-SEVENTH, 1953, at THREE o'clock in the afternoon (Daylight Saving Time).FERDINAND GERVAIS, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, May 19, 1953.34883-21-2 BEAUHARNOIS Fieri Facias de Terris Canada, Province of Quebec District of Beauharnois Superior Court, r THE QUEBEC FARM No.1041.-J 1 CREDIT BUREAU, a bo-\\ dy politic and corporate, having its head office at Quebec, district of Quebec, petitioner, vs NELSON BASKIN, of Hemmingford, district of Beauharnois, R.R.No.3, county of Huntingdon, respondant, Seized as belonging to the respondant: \"A Farm lying and situate in the Township of Hemmingford, county of Huntingdon, known and designated on the official plan and book of reference of the said township of Hemmingford as lot number fifty-five A (No.55A) in the second range of the Granted Lands, containing one hundred and six acres and twenty perches in superficies, less however a small strip of land measuring sixty feet by one hundred and twelve feet, detached from the south-west corner of the said lot and being a private cemetery.With the buildings thereon erected.\" To be sold at the parochial church door of the parish of St.Romain of Hemmingford, county of Huntingdon, district of Beauharnois, FRIDAY, the FIFTH day of JUNE, 1953, at TEN o'clock in the forenoon (Daylight Saving Time).HORACE VIAU, Sheriff's Office, Sheriff.Valleyfield, April 27, 1953.34744-18-2 BONAVENTURE Canada, Province of Quebec, District of Bonaventure New Carlisle.Superior Court, ( TJTECTOR LAFERTÉ, of the No.5684.< 11 City of Quebec, District (.of Quebec, Plaintiff, vs RE- 1766 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 mai 1953, Tome 86, N° 21 RENÉ C.CULLEN, de Carleton-sur-Mer, comté et district de Bova venture, défendeur, 1.Une certaine partie de terrain formant partie du lot numéro quarante et un C (41-C) du premier rang du canton de Carleton, situé à et touchant le côté nord-est de la propriété appartenant à Dame Louise Marcil, épouse de l'Honorable Charles Marcil, et commençant au coin nord-est de la propriété de la dite Dame Marcil et allant vers le nord dans la ligne de division entre les lots 41-C et 41-D pour une distance de vingt-huit pieds, de là, en allant vers l'ouest, une distance de cent vingt et un pieds jusqu'à un autre coin de la propriété de la dite Dame Charles Marcil et de là vers le sud une distance de vingt pieds jusqu'à ce que cette ligne rejoigne encore la propriété de la dite Dame Charles Marcil.2.Un lot de terre ou emplacement sis et situé et étant du côté nord du chemin public dans le village de Carleton, dans le comté de Bonaven-ture, connu et désigné comme partie du lot numéro quarante et un C (41-C) aux Plan et Livres de Renvoi du Bureau d'enregistrement de la deuxième division d'enregistrement du comté de Bonaventure, le dit lot de terrain ou emplacement mesurant cent quatre-vingr-seize pieds de front: sur la ligne allant du sud au nord du côté ouest cent quinze pieds; sur la ligne allant du sud au nord du côté est, cent pieds; en arrière, deux cents-douze pieds (212) mesure anglaise et plus ou moins et sans garantie quant aux mesures exactes; borné en front par la Baie des Chaleurs et le Chemin Public, d'un côté, à l'est, par la propriété occupée auparavant par M.Paul P.Cullen; en arrière et à 1 est par la balance du dit lot numéro quarante et un C, appartenant à M.William LeBlanc.Avec la maison, garage et glacière dessus érigées.Tel que la dite propriété existe actuellement, avec tous ses droits et accessoires mais sans, exception et réserve quelconque de la part du défendeur.Pour être vendus à la porte de l'église de Carleton, comté et district de Bonaventure, le TRENTIÈME jour du mois de JUIN, mil neuf cent cinquante-trois (1953) à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, .F.J.LEGRESLEY.New-Carlisle, le 16 mai 1953.34871-21-2-o NÉ C.CULLEN, of Carleton-sur-Mer, County and District of Bonaventure, Defendant.1.A certain piece or parcel of land forming part of lot number Forty-one C (41-C) of the First Range of the Township of Carleton, situated at and adjoining the north-eastern side of the property owned by Dame Louise Marcil, wife of the Honourable Charles Marcil, and starting from the north-eastern corner of the said Mrs Marcil's property and going towards the north in the division line between lots 41-C and 41-D a distance of twenty-eight feet, thence towards the west a distance of one hundred and twenty-one feet until it strikes another comer of the said Mrs.Marcil's property and thence towards the south a distance of twenty feet until it again strikes the said Mrs Marcil's property.2.A lot of land or emplacement situate, lying and being to the north side of the Public Road in the Village of Carleton, in the County of Bonaventure.known and designated as part of lot number Forty-one C (41-C) upon the Plan and in the Book of Reference deposited of record in the Registry Oflice of the Second Registration Division of the County of Bonaventure, containing the said lot of land or emplacement one hundred and ninety-six feet in front; on the line running from south to north on the west side one hundred and fifteen feet; on the line running from south to north on the east side one hundred feet: in rear 212 feet, English Measure and more or less without any guarantee as to exact measurements; bounded in front by the Baie de Chaleur and the Public Road, on one side to the east by the property formerly occupied by Mr.Paid P.Cullen; in the rear and to the east by the balance of said lot number Forty-One C belonging to Mr.William LeBlanc.With the house, garage and ice-house thereon erected.As the said property now subsits, with all its rights, members and appurtenances without exception and reserve of any king on the part of the defendant.To be sold at the parochial church door, at Carleton, county and district of Bonaventure, on the THIRTIETH day of the month of JUNE, nineteen hundred and fifty-three, (1953) at TEN o'clock in the forenoon.F.J.LEGRESLEY, Sheriff's Office, Sheriff.New Carlisle, May 16th, 1953.34871-21-2-0 GASPÊ Fieri Facias de Bonis et de Terris Rimouski, province de Québec Cour Supérieure, /T7PICERIE MODERNE N° 14325.\\ -E' ENRG de Ste-Anne des ' Monts, demandeur; vs PAUL-EMILE LAFONTAINE, de l'endroit appelé Cap-Seizc, dans la paroisse de Ste-Anne des Monts, comté de Gaspé, défendeur.Les droits de préemption, les défrichements, les améliorations et impenses sur le lot numéro dix (10) du rang F, canton Cap-Chat, avec bâtisses, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Bernard des Lacs, comté de Gaspé, le VINGT-DEUXIÈME jour de JUIN 1953, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du shérif, M.J.FURLONG.Percé, le 19 mai 1953.34894-21-2-o GASPÉ Fieri Facias de Bonis et de Terris Rimouski, Province of Quebec Superior Court, /\"DPICERIE MODERNE No.14325.{ -L' ENRG, of Ste-Anne des (Monts, plaintiff; vs PAUL-ÉMILE LAFONTAINE, of the place called Cap-Seize, in the parish of Ste.Anne des Monts, county of Gaspé; defendant.The pre-emption rights, land clearing, improvements and outlaying expenses for same on lot number ten (10) of range F, township of Cap-Chat, with buildings, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of St-Bernard des Lacs, county of Gaspé, the TWENTY-SECOND day of JUNE, 1953, at TEN o'clock in the forenoon.M.J.FURLONG, Sheriff's Office, Sheriff.Percé, May 19, 1953.34894-21-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 23rd, 1953, Vol.85, No.21 1767 QUÉBEC Fieri Facias Quebec, à savoir: / \"D AYMOND RICHARD et N° 69287.-j -tv sHENRI RICHARD, (.tous N deux de Pout-Rouge, comté de Portneuf, district de Quebec; contre RODOLPHE COTÉ, domicilié à Pont-Rouge, district de Québec, tant personnellement que pour autoriser son épouse aux fins des présentes et IRÈNE BÉDARD, épouse de Rodolphe Côté, domiciliée au même endroit, à savoir: Un lot actuellement connu et désigné comme 249-5 (deux cent quarante-neuf \u2014 cinq) du cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Jeannc de Neuville, maintenant en la paroisse de Pont-Rouge, comté de Portneuf, étant un lot mesurant 101 pieds au nord-ouest, 50 pieds au nord-est, 100 pieds au su-dest et 49 pieds au sud-ouest, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de Pont-Rouge, comté de Portneuf, le VINGT-SIXIÈME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, AIMÉ DION.Québec, 20 mai 1952.34895-21-2-o [Première insertion: 23 mai 1953.] [Deuxième insertion: G juin 1953.] Fieri Facias Cour de Magistrat Québec, à savoir: ( t AURENTIDE AUTO-N° 162457.< -L* MOBILES INC.corpo-( ration légale ayant son siège social à Québec; contre CHARLES AIMÉ VERRET, de Notre-Dame des Laurentides, comté de Québec, P.Q., à savoir: 1° Un emplacement faisant partie du lot N° 496 (quatre cent quatre-vingt-seize) du cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg, comté de Québec, maintenant situé en la paroisse de Notre-Dame des Laurentides, mesurant 65 pieds de front sur le chemin public par 110 pieds de profondeur, borné à l'ouest au chemin public, au nord à Lucien Verret, au sud et à l'est au vendeur, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.2° Un emplacement situé à 300 pieds du chemin public, mesurant 60 pieds de largeur par 70 pieds de profondeur, étant une partie du lot 490 (quatre cent quatre-vingt-seize) du cadastre officiel de la paioissc de Charlesbourg, comté de Québec, maintenant en la paroisse Notre-Dame des Laurentides, borné au nord, au sud et à l'ouest par la propriété du vendeur et à l'est par son chemin privé avec droit de passage sur le chemin privé du vendeur pour se rendre au chemin public avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.3° Un immeuble connu et désigné sous le N° 496 \"(quatre cent quatre-vingt-seize) du cadastre officiel pour la paroisse de Charlesbourg, comté de Québec, maintenant en la paroisse de Notre-Dame des Laurentides, à distraire cependant toutes les parties vendues et données suivant actes actuellement enregistrés et un emplacement que le vendeur se réserve à son choix pour être donné à Armand Verret d'ici deux ans des présentes, à défaut de quoi, la présente réserve sera annulée.4° Une partie du lot N° 19 (dix-neuf), du cadastre de Saint-Dunstan du Lac Beauport, mesurant un arpent de largeur par seize à dix-sept arpents de profondeur, borné d'un côter à QUEBEC Fieri Facias Quebec, to wit: / tj AYMOND RICHARD No.69287.{ lv and HENRI RI-(.CHARD, both of Pont-Rou-ge, County of Portneuf, district of Quebec: against RODOLPHE COTÉ, domiciled at Pont-Rouge, district of Quebec, personally, as well as to authorize his wife for purposes hereof and IRÈNE BÉDARD, wife of Rodolphe Côté, domiciled in the same place, to wit: A lot presently known and designated as 249-5 (two hundred and forty-nine-five) on the official cadastre for the parish of Ste-Jeanne-de-Neuville, now in the parish of Pont-Rouge, county of Portneuf, being a lot measuring 101 feet on the northwest, 50 feet on the northeast, 100 feet on the southeast and 49 feet on the southwest, with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of Pont-Rouge, county of Portneuf, the TWENTY-SIXTH day of JUNE next, at TEN o'clock in the forenoon (Daylight Saving Time).AIMÉ DION, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, May 20, 1953.34895-21-2 [First insertion: May 23, 1953] [Second insertion: June 0, 1953] Fieri Facias Magistrate's Court Quebec, to wit :/t AURENTIDE AUTO-No.102457.< -L* MOBILES INC.legal \\ corporation having its head office at Quebec; against CHARLES AIMÉ VERRET, of Notre-Dame des Laurentides, county of Quebec, P.Q., to wit: 1.An emplacement forming part of lot No.490 (four hundred and ninety-six) on the official cadastre of the parish of Charlesbourg, county of'Quebec, now situate in the parish of Notre-Dame des Laurentides, measuring 05 feet in front on the public highway, by 110 feet in depth, bounded on the west by the public highway, on the north, by Lucien Verret, on the south and on the cast, by the vendor, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.2.An emplacement situate at 300 feet from the public highway, measuring 60 feet in width by 70 feet in depth, being a part of lot 490 (four hundred and ninety-six) on the official cadastre of Charlesbourg, county of Quebec, now in the parish of Notre-Dame des Laurentides, bounded on the north, on the south and on the west, by the property of the vendor and on the east, by his private road, with right-of-way on the private road of the vendor to reach the public highway, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.3.An immoveable known and designated on No.490 (four hundred and ninety-six) on the official cadastre for the parish of Charlesbourg, county of Quebec, now in the parish of Notre-Dame des Laurentides, to subtract however, all parts sold and given according to presently registered deeds and an emplacement that the vendor reserves to his own choosing, to be given to Armand Verret as of this date to two years hence, in default of which, this present reserve shall be cancelled.4.A part of lot No.19 (nineteen), from the cadastre of Saint-Dunstan of Lake Beauport, measuring one arpent in width by sixteen to seventeen arpents in depth, bounded on one 1768 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 mai 1958, Tome 85, N° 21 l'ouest par Armand Verret et de l'autre côté à l'est par Lucien Verret, tel que le tout est actuellement avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendus à la porte de l'église paroissiale de Notre-Dame des Laurentides, comté de Québec, le DOUZIÈME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, AIMÉ DION.Québec, 6 mai 1953.34816-19-2-0 [Première insertion: 9 mai 1953] (Deuxième insertion: 23 mai 1953] side, on the west, by Armand Verret, and on the other side, on the east, by Lucien Verret, as the whole presently stands, with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the door of the parish church of Notre-Dame des Laurentides, county of Quebec, the TWELFTH day of JUNE next, at TEN o'clock in the forenoon (Daylight Saving Time).AIMÉ DION, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, May 6, 1953.34816-19-2 (First insertion: May 9, 1953] [Second insertion: May 23, 19531 ROBERVAL Fieri Facias de Terris District de Roberval Cour Supérieure, / /^AGNON & FRÈRES DE N° 14302.< ROBERVAL LTÉE v Corps politique légalement constituée ayant un bureau d'affaires à Roberval, District de Roberval.Demandeur, vs ROSAIRE CHALIFOUR, St-Jérome, District de Roberval.Avis est par les présentes donné que les terres et héritages sus-nientionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieu respectifs, tel que mentionné plus bas à savoir: Une maison construite sur le lot de terre portant le numéro quarante-un (N° 41) du rang sept (7) du canton Caron et les droits y adhérant, propriété de Monsieur Rosaire Chalifour, de St-Jérôme.Pour être vendu à la Salle paroissiale de St-Jérôme (Metabetchouan) Comté Lac St-Jean District de Roberval, Province de Québec, le VINGT-TROISIÈME jour de JUIN 1953 à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, ANTOINE TREMBLAY.Palais de Justice de Roberval District de Roberval ce 16 mai 1953.34872-21-2-0 ROBERVAL Fieri Facias de Terris District de Roberval Superior Court, ( pi AG NON & FRÈRES DE No.14302.1 VJ ROBERVAL LTÉE, l a body politic legally incorporated, having its place of business at Roberval, District of Roberval.plaintiff, vs ROSAIRE CHALIFOUR, St.Jérôme, District of Roberval.Notice is hereby given that the lands and he-riditnments, below mentioned, have been seized and will be sold at their respective time and place, as hercinunder mentioned, to wit: A house built on the lot of land bearing number forty-one (41) of the seventh range (7), of the township of Caron and the rights adhering thereto, property of Mr.Rosaire Chalifour, of St.Jérôme.To be sold at the parochial hall of St.Jérôme (Metabetchouan) County of Lake St.John, District of Roberval, Province of Quebec, the TWENTY-THIRD day of JUNE, 1953, at TEN o'clock in the forenoon.ANTOINE TREMBLAY, Sheriff's Office, Sheriff.Court House of Roberval, District of Roberval, this 16th day of May, 1953.34872-21-2 SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Terris District de St-François, Cour Supérieure, / t *»OFFICE DU CRÉDIT N° 2517.J -L» AGRICOLE DU QUÉ-(BEC, corps politique et incorporé, ayant son siège social à Québec, Requérant vs ALBERT BERGERON, de Scotstown, district de St-François, Intimé.Comme appartenant au dit Intimé: Ces certains lots ou étendues de terre connus et désignés sur le Plan de Cadastre et dans le livre de Renvoi pour le canton de Hampden comme étant: 1.Les lots numéros deux cent quarante-sept (247) et deux cent quarante-huit (248) sur le plan officiel du cadastre et dans le livre de renvoi pour le canton de Hampden, autrefois connus par la subdivision primitive dudit canton comme les lots numéros trente-sept et trente-six, dans le premier rang Victoria sud ; sauf et excepté les parties d'iceux vendues par Alexander-Murray à John McLeod par acte de vente passé devant J.-I.Mackie, notaire, le onze mars 1875 et enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Compton, au Reg.B.Vol.19, numéro 10, 105A, et dans ledit acte de vente décrites comme suit: Commençant à la ligne des hautes eaux au centre du chemin Victoria sur le côté nord du ruisseau Otter; de là, allant vers l'est, sur le SAINT FRANCIS Fieri Faicas de Terris District of St-Francis, Superior Court, ( /QUEBEC FARM CREDIT No.2517.< BUREAU, body politic I and incorporated, having its head office at Quebec, applicant; vs ALBERT BERGERON, of Scotstown, district of St-Fran- * cis, appellee.As belonging to the said Appellee: Those certain tracts or lots of land known and described on the Cadastral Plan and in the Book of Reference for the Township of Hampden as being: 1.The lots numbers two hundred and forty-seven (247), and two hundred and forty-eight
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.