Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 6 (no 23)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1953-06-06, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 85, N° 23 1881 Vol.85, No.23 \t¦\t'0 \t\tWÊÊÊÊ \t¦\t \t\t¦ * Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de ld province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette de Québec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUEBEC Quebec, samedi 6 juin 1953 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de Ta Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, June 6th, 1953 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter.6270 1882 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 juin 1953, Tome 85, N° 23 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, depart et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 26G lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.33898 \u20141-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: S7.per ear N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document mamber.REDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.33898 \u2014 1-52 Lettres patentes Adélard et Gustave Lépine, Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du trente avril 1953, constituant en corporation : J.-Arthur Juneau, industriel, Roméo Paradis, Adalbert Poulin, tous deux employés, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs de pompes funèbres, sous le nom de \"Adélard et Gustave Lépine, Ltée\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le trente avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Letters Patent Adélard et Gustave Lépine, Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirtieth of April 1953, incorporating: J.-Arthur Juneau, industrialist, Roméo Paradis, Adalbert Poulin, both employees, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of undertakers, under the name of \"Adélard et Gustave Lépine, Ltée\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of S100 each.The head office of the company shall be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, the thirtieth day of April 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General. QUEBECIOFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 6th, 1958, Vol.85, No.28 1883 Aluminum Packaging Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richclièrc, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du trentième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, de lacité d'Outremont, Bernard Diamond, avocat, Larry Smith, comptable, Gilbert Howard, marchand, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de ferronnerie, sous le nom de \"Aluminum Packaging Limited\", avec un capital de §40,000, divisé en 200 actions ordinaires de S100 chacune et 200 actions priviléeiécs de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce trentième jour d'avril 1953.- L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Aluminum Packaging Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q.1941, bearing date the thirtieth day of April, 1953, incorporating: Louis Orenstein, advocate, of the City of Outrcmont, Bernard Diamond, advocate, Larry Smith, accountant, Gilbert Howard, merchant, of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in hardware, under the name of \"Aluminum Packaging Limited\", with a capital stock of S40.000, divided into 200 common shares of 8100 each, and 200 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirtieth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Armstrong Funeral Chapel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lièrc, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du trentième jour d'avril 1953.constituant en corporation: William Guy Armstrong, Colin Campbcl Leslie, tous deux entrepreneurs de pompes funèbres, Georges Douglas Armstrong, dentiste, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre et exercer le commerce de directeurs funéraires, entrepreneurs de pompes funèbres, embaumeurs, sous le nom de \"Armstrong Funeral Chapel Inc.\", avec un capital de 840,000, divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 3426 avenue du Parc, cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce trentième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Bel Air Clothing Inc.Vêtements Bel Air Inc.»' Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec, représenté par M.C.LaRichc-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du vingt et un avril 1953, constituant en corporation: Joseph Moorc, tailleur, de Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska, Marcel Roberge, agent manufacturier, de la cité de Québec, Jean-M.Roberge, agent manufacturier, de Sillery, ces deux derniers du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer généralement le commerce et ^'industrie de manufacturier de vêtements, sous le nom de \"Bel Air Clothing Inc.\" \u2014 \"Vêtements Bel Air Inc.\", avec un capital de 850,000, divisé en 200 actions communes d'une valeur au pair de S100 chacune, et en 600 actions privilégiées d'une valeur au pair de 850 chacune.Armstrong Funeral Chapel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirtieth dUy of April, 1953, incorporating: William Guy Armstrong, Colin Campbell Leslie, both undertakers, Georges Douglas Armstrong, dentist, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To undertake and carry on the business of funeral directors, undertakers, morticians, em-balmers, under the name of \"Armstrong Funeral Chapel Inc.' ', with a capital stock of 840,000, divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 3426 Park Avenue, in the city of Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Bel Air Clothing Inc.Vêtements Bel Air Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-first of April 1953, incorporating: Joseph Moore, tailor, of Victoriaville, judicial district of Artha-baska, Marcel Roberge, manufacturing agent, of the city of Quebec, Jean-M.Roberge, manufacturing agent, of Sillery, the two latter of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry, on the general business and deal in as manufacturer of wearing apparel, undcè the name of \"Bel Air Clothing Inc.\" \u2014 \"Vêtements Bel Air Inc.\", with a capital stock of 850,000, divided into 200 common shares of a par value of $100 each and 600 preferred shares of a par value of $50 each. 1884 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 juin 1953, Tome 86, N° 23 Le siège socud de la compagnie sera à Laurier-ville, district judiciaire d'Arlhabaska.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Blackio Automobile Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi îles compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelièrc, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-cinquième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Jack Lightstone, avocat, Yvonne Bélanger, et Roselyn Soloway, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter, maintenir, opérer et diriger des garages, sous le nom de \"Blackie Automobile Co.Ltd.\", avec un capital de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune et 200 actions privilégiées d'une va'eur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-cinquième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Bota & Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-deux avril 1953, constituant en corporation: Clarence Francis McCaffrey, c.r., James Pettigrew Diplock, procureurs et Mildred Calla-ghan, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'appareils de radio et de télévision, machines électroniques et accessoires électriques, sous le nom de \"Bota & Company Ltd.\", avec un capital de $20,000,-divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Bristol Transformers Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du premier mai 1953, constituant en corporation: Jack Lighstone, Leo Lavut, avocats, Roslyn Soloway, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de machinerie, générateurs, moteurs, accessoires et articles se rapportant ou connexes en aucune manière à la production, le contrôle ou à l'application de l'électricité, sous le nom de \"Bristol Transformers Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de 8100 chacune.The head office of the company shall be at Laurierville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, the twentv-first day of April, 1953.L.DÉSILETS, 3^950 Deputy Attorney General.Blackic Automobile Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-fifth day of April, 1953, incorporating: Jack Lights-tone, advocate, Yvonne Bélanger and Roslyn Soloway, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To keep, maintain, operate and manage garages, under the name of \"Blackic Automobile Co.Ltd.\", with a capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of the par value of $100 each and 200 preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fifth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Bota & Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-second day of April, 1953, incorporating: Clarence Francis McCaffrey, Q.C., James Pettigrew Diplock, barristers, and Mildred Callaghan, secretary all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in radio and television sets, electronic machines and electrical appliances, under the name of \"Bota & Company Ltd.\", with a capital stock of 820,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-second day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Bristol Transformers Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the first day of May, 1953, incorporating: Jack Lightstone, Leo Lavut, advocates, Roslyn Soloway, stenographer, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal with machinery, generators, motors, supplies and articles appertaining to or in any way connected with production, control or application of electricity, under the name of \"Bristol Transformers Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of S100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June Gth, 1953, Vol.85, No.S3 1885 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Brosnan Chibougamau Mines Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichc-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-quatrième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant, Clifford George Meck, Charles Eric Humphrey, Guy Ambrose Miller, teneurs de livres, Cecil Bruce Cooke, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Brosnan Chibougamau Mines Limited\" (Livre de responsabilité personnelle), avec un capital de $4,000,000, divisé en 4,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le- siège social de la compagnie sera au village de Chibougamau district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-quatrième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Canada Moulders Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, i.a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt et un avril 1953, constituant en corporation: Charles-Joseph Gélinas, avocat et conseil en loi de la reine, Paul Gérin-Lajoie, Jean Geof-frion, avocats, tous trois d'Outremont, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de tous articles faits de matières plastiques, verres, argiles, plâtres, bois, métaux, sous le nom de \"Canada Moulders Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune, et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 7944, 14ième avenue, Ville St-Michel, district judiciaire de Montréxl.Daté du bureau du Procureur général le vingt et un avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Canado Construction Ltée Canado Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Brosnan Chibougamau Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclièrc, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date thé twneyt-fourth day of April, 1953, incorporating* Ernest William Mockridge, manager, Clifford Georges Meek, Charles Eric Humphrey, Guy Ambrose Miller, bookkeepers, Cecil Bruce Cooke, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Brosnan Chibougamau Mines Limited\" (No Personal Liability), with a capital stock of $4,000,000, divided into 4,000,000 shares of SI each.The shareholders shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agrceed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at the village of Chibougamau, in the judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of April, 1953.L.DÉSILETS.34950-o Deputy Attorney General.Canada Moulders Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richeliè.e, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bcanng date the twenty-first day of Aprrl, 1953, incorporating: Charles-Joseph Gélinas, advocate and Queen's Counsel, Paul Gérin-Lajoie, Jean Geoffrion, advocates, all three of Outremont, judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all articles made of plastic, glass, clay, plaster, wood, metals, under the name of \"Canada Moulders Inc.\", with a capital stock of S40.000, divided into 200 common shares of a par value of 8100 each, and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 7944, 14th Avenue, Town of St-Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-first day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attoruey General.Canado Construction Ltée Canado Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with_section 2, chapter 1886 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, G juin 1958, Tome 85, N° 23 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du premier mai 1953, constituant en corporation: Jean-Louis Hamclin, entrepreneur général, J.Emile Trépanicr, agent, Marc-Y.Trépanier, dentiste, tous de Saint-Adelphe, district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Canado Construction Ltée\" \u2014 \"Canado Construction Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Adelphe, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le premier mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.276, R.S.Q., 1941, bearing date the first day of May, 1953, incorporating: Jean-Louis Hamelin, general contractor, J.Emile Trépanier, agent, Marc Y.Trépaniei, dentist, all of Saint-Adelphe, judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Canado Construction Ltée\" \u2014 \"Canado Construction Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Adelphe, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.Cape Breton Metals Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Colleen Shirley Abbott, Eleanor Wallace, secrétaires, filles majeures, William James Stewart, William Ernest Regan, avocats, James Hugh Gilmour Wallace, étudiant en droit, Joseph Francis Stewart, et David Burrel Mac Williams, courtiers, tous des cité de Toronto, dans la province d'Ontario, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Cape Breton Metals Limited\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de $5,000,000, divisé en 5,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle* au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à 134 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-deuxième jour d'avril 1953.L'Assistant-procu reur généra 1, 34950 L.DÉSILETS.Cape Diamond Construction, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-huitième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Desmond \"Rourke, entrepreneur, de Sillery, Vernal Lewis McBain, entrepreneur, de Ste-Foy, Louis Boulanger, vendeur, de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Diriger et exercer le commerce de constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de \"Cape Diamond Construction, Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la cité de Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-huitième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Cape Breton Metals Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented bv Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-second day of April, 1953, incorporating: Colleen Shirley Abbott, Eleanor Wallace, secretaries, spinsters, William James Stewart, William Ernest Regan, solicitors, James Hugh Gilmour Wallace, student-at-law, Joseph Francis Stewart, and David Burrell MacWilliams, brokers, all of the city of Toronto, in the Province of Ontario, for the following purposes : To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Cape Breton Metals Limited\" (No Personal Liability), with a capital stock of $5,000,000, divided into 5,000,000 shares of $1 each.The shareholders shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the colnpany for its shares.The head office of the company will be at 134 St.James Street, West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Cape Diamond Construction, Inc.* Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-eighth day of April, 1953, incorporating: Desmond Rourke, contractor, of Sillery, Vernal Lewis McBain, contractor, of Ste-Foy, Louis Boulanger, salesman, of Quebec, all in the judicial district of Quebec, for the following purposes: To conduct and carry on the business of builders and contractors, under the name of \"Cape Diamond Construction Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec city, judicial district of Quebec.Dated àt the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of April, 1953.r-*MfeL.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 6th, 1953, Vol.So, No.23 1887 Casualty Adjustment Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941.des lettres patentes en date du premier mai 1953, constituant en corporation: E.Grant Cochrane, William J.Fleming, ajusteur^, et Jeanne-Cécile Ranger Cochrane, secrétaire, épouse séparée de biens de E.Grant Cochrane et dûment autorisée par lui, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme courtiers d'assurances et agir comme agents et ajusteurs d'assurances, sous le nom de \"Casualty Adjustment Company Limited\", avec un capital de 849,000 divisé en 490 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Casualty Adjustment Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 270, S.R.Q.1941, bearing date the first day of May, 1953, incorporating: E.Grant Cochrane, William J.Fleming, adjusters, and Jeanne-Cécile Ranger Cochrane, secretary, wife separate as to property of E.Grant Cochrane, and duly authorized by him, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of insurance brokers and to act as insrrrarrce agents and as insurance adjusters, under the name of \"Casualty Adjustment Company Limited\", with a capital stock of 849,000, divided into 490 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this first dav of May, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Chambre de Commerce des Jeunes, Chambre de Commerce des Jeunes, Salaberry de Valleyfield Salaberry de Valleyfield Avis est donné qu'en vertu des dispositionsde Notice is hereby given that under Part III of la troisième partie de la Loi des compagnies de the Quebec Companies' Act, letters patent have Québec, il a'été accordé par le Lieutcnant-gouvcr- been issrrcd by the Lieutenant-Governor of the neur de la province de Québec, représenté par M.Province of Quebec, represented by Mr.C.La- C.LaRichelièrc, conformément à l'article 2, cira- Richelière, in conformity with section 2, chapter pitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en 276, S.R.Q., 1941, bearing date the twenty-fourth date du vingt-quatre avril 1953, constituant en day of April, 1953.to incorporate as a corporation corporation sans capital-actions: Normand St- without share capital: Normand St.Jean, sales Jean, gérant des ventes, Jean-Marc Clermont, manager, Jean-Marc Clermont, Rolland Côté, Rolland Coté, Gérard Cadieux, Jacques Lcbeuf, Gérard Cadieux, Jacqrres Lebcuf, Paul-Heuri Paul-Henri Lemyre, marchands, Georges Le- Lemyre, merchants, Georges Lecomptc, contrac- compte, entrepreneur, Raorrl Lupicrr, notaire, tor, Raoul Lupien, notary, Dollard Pilon, pro- Dollard Pilon, professeur, Raymond Lavoie, fessor, Raymond Lavoie, photographer, Michel photographe, Michel Pichc, nettoyeur, James Piehé, cleaner, James Roberge, technician, Ar- Roberge, technicien, Armand Pruneau, garagis- mand Primeau, garage-keeper, all of Salaberry- te, tous de Salaberry de Valleyfield, district ju- de-Vallcyficld, judicial district of Beauharnois, diciaire de Beauharnois, pour les objets suivants: for the following purposes: Grouper en «association les jeunes hommes de To group into an association the young men la Cité de Salabcrry-de-Valleyficld, pour en of the city of Salaberry-dc-Valleyfield, to form faire une équipe, sous le nom de \"Chambre de into a group, under the name of \"Chambre de Commerce des Jeunes, Salaberry de Valleyfield\".Commerce des Jeunes, Salaberry de Valleyfield\".Le montant auquel sont limités les revenus The amount to which the immoveable proper- annuels des biens immobiliers que la corporation ty which the corporation may hold is to be limi- peut posséder, est de 82,000.ted, is 82,000.Le siège social de la corporation sera à Sala- The head office of the corporation will be at berry-de-Valleyfield, district judiciaire de Beau- Salaberry-de-Valleyfield, judicial district of Beauharnois.harnois.Daté du bureau du Procureur général le vingt- Dated at the office of the Attorney General, quatre avril 1953.this twenty-fourth day of April, 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 34950-o L.DÉSILETS.34950 Deputy Attorney General.Chesterfield Moderne Cie Ltée Chesterfield Moderne Cie Ltc*e Modern Chesterfield Co.Ltd.Modern Chesterfield Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été the Quebec Companies' Act, letters patent have accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- been issued by the Lieutenant-Governor of the vince de Québec, représenté par M.C.LaRiche- Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi- lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, chelière, in conformity with section 2, chapter S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirtieth day trente avril 1953, constituant en corporation: of April, 1953, incorporating: André Legault, André Legault, manufacturier, de Ville St- manufacturer, of Ville St-Michel, Hector Legault, Michel, Hector Legault, Rémi Legault, mar- Rémi Legault, merchants, of Montreal, all of the chands, de Montréal, tous du district judiciaire judicial district of Montreal, for the following de Montréal, pour les objet suivants: purposes: La fabrication, la vente des meubles meublants The manufacture, the sale of household goods et effets mobiliers de tous genres, sous le nom and furniture of all kinds, under the name of 1888 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, G juin 1953, Tome 85, N° 23 de \"Chesterfield Moderne Cie Ltée\" \u2014 \"Modem Chesterfield Co.Ltd.\", avec un capital de S90.000, divisé en 9C0 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera au numéro 8725, lOième Ave, Ville St-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.\"Chesterfield Moderne Cie Ltée\" \u2014 \"Modem Chesterfield Co.Ltd.?, with a capital stock of 890,000, divided into 900 shares of 8100 each.The head office of the company will be at number 8725, 10th Avenue, Ville St-Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.Elcctrolinc Television Equipment Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneu.de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichc-lière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-troisième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Arono-vitch, avocats, Freda Pomcrance, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers, marchands, négociants de tous appareils émetteurs ou récepteurs de télévision ou radio aussi bien que de toutes pièces ou outillage s'y rapportant, sous le nom de \"Electroline Television Equipment Inc.\", avec un capital de 840,000, divisé en 150 actions ordinaires de S100 chacune et 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-troisième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Elgo Trading Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du huit mai 1953, constituant en corporation: Jean Monette, procureur, de Longueuil, Pauline Cabana, Rita Angers, sténographes, filles majeures, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce, transiger et négocier des valeurs et publier des renseignements financiers, sous le nom de \"îllgo Trading Limited\", avec un capital de 810,000, divisé en 10,000 actions de 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.E.& R.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelièie, conformément à l'article 2, chapitre 270, R.S.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Harry Evin, marchand, Doris Aber Evin, épouse séparée de biens dudit Harry Evin, Benjamin L.Louis, avocat, tous des cité et dis- Elcctrolinc Television Equipment Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformitv with section 2, chapter 270.R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-third day of April, 1953, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, advocates, Freda Pomerance, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers, dealers in or with all television or radio sending or receiving sets as well as all parts of, or equipment, for, under the name of \"Electroline Television Equipment Inc.\", with a capital stock of 840,000, divided into 150 common shares of S100 each, and 250 preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of April, 1953.L.DÉSILETS.34950-o Deputy Attorney General.Elgo Trading Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eight day of May, 1953, incorporating; Jean Monette, barrister, of Longueuil, Pauline Cabana, Rita Angers, stenographers, spinsters, of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal and trade in and with securities, to publish financial information, under the name of \"Elgo Trading Limited\", with a capital stock of $10,000, divided into 10,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eighth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.E.& R.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-second day of April, 1953, incorporating: Harry Evin, merchant, Doris Aber Evin, wife separate as to property of the said Harry Evin, JBenjamin L.Louis, advocate, all of the city and judicial dis- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 6th, 1953, Vol 85, No.23 1889 trict judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et négocier des appareils de toutes descriptions, sous le nom de \"E.& II.Inc.\", avec un capital de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-deuxième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Exclusive Leather Products Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenter par M.C.LaRi-chelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-quatrième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Hyman Sedeioff, manufacturier, Sara Trachtenberg, ménagère, épouse con-tractucllemcnt séparée de biens dudit Hyman Sederoff, Jack Mechanic, manufacturier, Bernice Rissman, ménagère, épouse contracluellement séparée de biens dudit Jack Mechanic, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires qui consistent à manufacturer et faire le commerce de bourses pour enfants produits tricotées, cosmétiques, sacs, ceintures et nouveautés aussi bien qu'accessoiics faits de cuir, plastiques, draps et autres substances similaires, sous le nom de \"Exclusive Leather Products Corp.\", avec un capital de 850,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-quatrième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureurgénéral, 34950 L.DÉSILETS, Franklin Electrical Supply Co.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieu tenant -gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichc-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes' en date du vingt-troisième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Lewis Shapiro, Moe Shapiro, marchands, Hyman Eric Feigelson, avocat, James Topping, surintendant, tous des cité et district judiciaire de Montrézl, pour les objets suivants: Exercer les affaires qui consistent à manufacturer et faire le commerce d'outillage électrique et motorisé, pièces, dispositifs et accessoires nouveautés, ferronnerie, ameublement, sous le nom de \"Franklin Electrical Supply Co.\", avec un capital de $400,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-troisième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.trict of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and trading in apparel of all description, under the name of \"E.& R.Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-second day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Exclusive Leather Products Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies 'Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fourth day of April, 1953, incorporating: Hyman Sederoff, manufcturcr, Sara Trachtenberg, housewife, wife contractually separate as to property of the said Hyman Sederoff, Jack Mechanic, manufacturer, Bernice Rissman, housewife, wife contractually separate as to property of the said Jack Mechanic, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in children's purses, knitting poducts, cosmetics, bags, belts and novelties, as well as accessories thereof, made of leather, plastics, cloth and similar materials, under the name of \"Exclusive Leather Products Corp.\", with a capital stock of 850,000, divided ito 250 common shares of $100 each, and 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Franklin Electrical Supply Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelièrc, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-third clay of April, 1953, incorporating: Lewis Shapiro, Moc Shapiro, merchants, Hyman Eric Feigelson, advocate, James Topping, superintendent, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in electrical and automotive equipment, parts, appliances and accessories, novelties, hardware, furniture, under the name of \"Franklin Electrical Supply Co.\", with a capital stock of $400,000, divided into 10,000 common shares of a par value of S10 each and 30,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal, Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General. 1890 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, G juin 1953, Tome 85, N° 23 G.E.Bellivcau Liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 270, R.S.Q.1911.des lettres patentes, en date du vingt et un avril 1963, constituant en corporation: Gérard-E.Bellivcau, entrepreneur, Ulric Lernay, plombier, tous deux de Ste Rose, Laurent-R.Desmarais, comptable, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en plomberie, entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"G.E.Belliveau Ltée\", avec un capital de $40,000, divisé en 800 actions de S50 chacune.' Le siège social de la compagnie sera à Ste-Rose, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt et un avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.G.E.Bellivcau Ltée Notice is hereby given that' under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelièrc, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-first day of April 1953, incorporating: Gérard-E.Bellivcau, contractor, Ulric Lemay, plumber both of St.Rose, Laurent-R.Desmarais, accountant, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business contractors in plumbing, general contractors and builders, under the name of \"G.E.Belliveau Ltée\" with a capital stock of 840,000, divided into 800 shares of 850 each.The head office of the company shall be at St.Rose judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-first day of April 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.Gould Auto Supply Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Îirovince de Québec, représenté par M.C.La-tichelière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingtième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Harold S.Freeman, Abraham IL .1.Zai-tlin, avocats, Samuel Joseph Gould, Murray Yanow, marchands, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires comme manufacturiers et marchands d'automobiles, moteurs, engins, machines, carburateurs, accessoires, pièces: et maintenir et exploiter des garages, sous le nom de \"Gould Auto Supply Co.\".Le capital-actions de la compagnie sera composé de 4,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et 800 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingtième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général.34950 L.DÉSILETS.Harrow Glove Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en daet du vingt-troisième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Sydney Phillips, avocat, Rose-Marie Bourgoing, Tessy Frankel, toutes deux secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands, manufacturier de gants, sous le nom de \"Harrow Glove Company\", avec un capital de 840,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Gould Auto Supply Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richclièrc, in conformity with section 2, chapter 27G, R.S.Q.1941, bearing date the twentieth day of April, 1953, incorporating: Harold S.Freeman, Abraham H.J.Zaitlin, advocates.Samuel Joseph Gould, Murray Yanow, merchants, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturers and dealers in automobiles, motors, engines, machines, carburators, accessories, parts: and to maintain and operate garages, under the name of \"Gould Auto Supply Co.\", The capital stock of the company shall consist of 4,000 common shares of no par value and 800 preferred shares of the par value of 8100.each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of April, 1953.L.DÉSILETS.34950-o Deputy Attorney General.Harrow Glove Company Notice is hereby given htat under Part f of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-third day of April, 1953, incorporating: Sydney Phillips, advocate, Rose-Marie Bourgoing, Tcssy Frankcl, both secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a dealer, manufacturer of gloves, under the name of \"Harrow Glove Company\", with a capital stock of S40,000, divided into 300 preferred shares having a par value of 8100 each and 1,000 common shares having a par value of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 6th, 1953, Vol.85, No.28 1891 Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-troisième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Henri Gilbert & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-Iière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du vingt-quatre avril 1953, constituant en corporation: Henri Gilbert, Paul-Armand Gilbert, et Jean-Paul Gilbert, marchands, tous de La Tuque, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de cigares, cigarettes et tabac, et d'épiceries, sous le nom de \"Henri Gilbert & Fils Ltée\", avec un capital de 865,000, divisé en 250 actions privilégiées de S100 chacune et en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à La Tuque, comté de Laviolette, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day od April, 1953.L.DÉSILETS.34950-o Deputy Attorney General.Henri Gilbert & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fourth day of April 1953, incorporating: Henri Gilbert, Paul-Armand Gilbert, and Jean-Paul Gilbert, merchant, all of La Tuque, judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in cigars, cigarettes, tobacco, and groceries, under the name of \"Henri Gilbert & Fils Ltée\", with a capital stock of 865,000, divided into 250 preferred shares of 8100 each, and 400 common shares of 8100 each.The head office of the company shall be at La Tuque, county of Laviolette, judicial district of Québec.Dated at the.office of the Attorney General, the twenty-fourth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.Hôtel Union Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du -ingt-quatre avril 1953, constituant en corporation: Lucien Dugré, hôtelier, Louis-A.Gau-dreau, agent d'immeubles, Jean Gaudreau, comptable, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôtellerie, sous le nom de \"Hôtel Union Inc.\", Le capital-actions de la compagnie est divisé en 1,000 actions ordinaires de $100 chacune, et en 2,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général le vingt-quatre avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Imprimerie Astra Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière.conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt et un avril 1953, constituant en corporation: Bernard Dumouchel, Lucien Lajeunesse, imprimeurs, de Beauharnois, Laurent Cyr, journaliste, Maurice Constant, imprimeur, de Valleyfield, tous du district judiciaire de Beauharnois, pour les objets suivants: Pratiquer l'industrie et faire le commerce d'imprimeurs, d'éditeurs, sous le nom de \"Imprimerie Astra Limitée\", avec un capital de S50.000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 1,000 actions privilégiées de 810 chacune.Hôtel Union Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have \u2022 been issrrcd by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q.1941.bearing date the twenty-fourth day of April 1953, incorporating: Lucien Dugré, hotclkeeper, Louis-A.Gaudreau, real estate agent, Jean Gaudreau, accountant, all of Sherbrooke, judicial district of St.Francis, for the following purposes: To carry on the business of hotelkeeper, under the name of \"Hôtel Union Inc.\", The capital stock of the company is divided into 1,000 common shares of $100 each, and 2,000 preferred shares of 8100 each.The head office of the company shall be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-fourth day of April 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.Imprimerie Astra Limitée Notice is hereby given that under Part, I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q., 1941.bearing date the twenty-first day of April, 1953, incorporating: Bernard Dumouchel, Lucien Lajeunesse, printers, of Beauharnois, Lourent Cyr, journalist, Maurice Constant, printer, of Valleyfield, all of the judicial district of Beauharnois, for the following purposes: To operate as and carry on the business of printers, editors, rrndcr the name of \"Imprimerie Astra Limitée\", with a capital stock of 850,000, divided into 4,000 common shares of S10 each and into 1,000 preferred shares of 810 each. 1892 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 juin 1953, Tome 85, N° 28 Le siège social de la compagnie sera à Beau- The head office of the company will he at harnois, district judiciaire de Beauharnois.Beauharnois, judicial district of Beauharnois.Daté du bureau du Procureur général le vingt Dated at the office of the Attorney General, et un avril 1953.this twenty-first day of April, 1953.L Assistant-procureur général, L.DESILETS, 34950-o L.DÉSILETS.34950 Deputy Attorney General.International Fur Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la-province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du premier mai 1953, constituant en corporation: Louis Fitch, c.r., de Westmount, Nathan A.Levitsky, avocat, Rose Markis, secrétaire, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce et manufacturer des peaux, fourrures et articles semblables, sous le nom de \"International Fur Company\", avec un capital de 8100,000, divisé en 500 actions ordinaires de 8100 chacune et 500 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Isolation Sherbrooke Limitée Sherbrooke Insulation Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du vingt-quatre avril 1953, constituant en corporation: André Dubé, homme d'affaires, Paul Custeau, dessinateur, Ovila Drouin, tricoteur, André Trotticr, comptable agréé, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Exercer le commerce de matériaux de construction et djune façon particulière le commerce de matériaux dits \"d'isolation\", sous le nom de \"Isolation Sherbrooke Limitée\" \u2014 \"Sherbrooke Insulation Limited\", avec un capital de S40.000, divisé en 1,000 actions de 840 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général le vingt-quatre avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.International Fur Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the first day of May, 1953, incorporating: Louis Fitch, Q.C., of Westmount, Nathan A.Levitsky-, advocate, Rose Markis, secretary, of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes : To deal in, manufacture in skins, furs and similar articles, under the name of \"International Fur Company\", with a capital stock of 8100,000, divided into 500 common shares of 8100 each, and 500 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1953.L.DÉSILETS, ' 34950-o Deputy Attorney General.Isolation Sherbrooke Limitée Sherbrooke Insulation Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chclière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, heating dale the twenty-fourth day of April, 1953, incorporating: André Dubé, business-man, Paid Custeau, designer, Ovila Drouin, knitter, André Trotticr, chartered accountant, all of Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis, for the following purposes: To deal in building materials and in a special way, in insulation materials, under the name of \"Isolation Sherbrooke Limitée\" \u2014 \"Sherbrooke Insulation Limited\", with a capital stock of 840,000, divided into 1,000 shares of 840 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.J.E.Gosselin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur, de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-quatre avril 1953, constituant en corporation: Joseph-Elie Gosselin, entrepreneur plombier, Heuri Gosselin, et Jean-Paul Gosselin, plombiers, tous d'Amos, district judiciaire d'Abi-tibi, pour les objets suivants: Exercer le commerce et l'industrie d'entrepreneurs en électricité, en plomberie, ouvrage de J.E.Gosselin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fourth day of April, 1953, incorporating: Joseph-Elie Gosselin, plumbing contractor, Henri Gos«\"»Iin, and Jean-Paul Gosselin, plumbers, all of Aiaos, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To carry on the business and.work of contractors in electricity aud plumbing, work in sheet QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 6th, 1953, Vol 85, No.23 1893 métal en feuilles, sous le nom de \"J.E.Gosselin Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune et en 300 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Amos, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général le vingt-quatre avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.metal, under the name of \"J.E.Gosselin Inc.\", with a capital of $40,000, divided into 1,000 preferred shares of S10 each and into 300 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at Amos, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-fourth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.Kay Thread Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-trois avril 1953, constituant en corporation: Moses Kraskin, marchand, Abram Gutman, vendeur, Solomon Brandt, technicien, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce ou le négoce de tissus de toutes sortes, sous le nom de \"Kay Thread Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune et 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Kay Thread Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richclière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-third day of April, 1953, incorporating: Moses Kraskin, merchant, Abram Gutman, ssalesman, Solomon Brandt, technicien, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in or with fabrics of every sort, under the name of \"Kay Thread Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 3,000 preferred shares of $10 each, and 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-third day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.La Cie de Placements Cavalier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-deux avril 1953, constituant en corporation: J.-Claude Nolin, avocat, Jean-Marie Raymond, étudiant, Gilles Durand, étudiant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de placements, sous le nom de \"La Cie de Placements Cavalier Inc.\", avec un capital de S40.000, divisé en 350 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune et en 50 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.La Compagnie de Constructions Idéales Inc.Ideal Constructions Company Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q, 1941, des lettres patentes, en date du vingt-cinq avril 1953, constituant en corporation: Edgar Bouchard, constructeur, Jacques Décary, Neil L.King, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: La Cie de Placements Cavalier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-second day of April 1953, incorporating: J.-Claude Nolin, advocate, Jean-Marie Raymond, student, Gilles Durand, student, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate as an investment company, under the name of \"La Cie de Placements Cavalier, Inc.\" with a capital of 840,000, divided into 350 preferred shares of a nominal value of $100 each, and 50 common shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-second day of April 1953.L.DÉSILETS.34950 Deputy Attorney General.La Compagnie de Constructions Idéales Inc.Ideal Constructions Company Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fifth day of April, 1953, incorporating: Edgar Bouchard, builder, Jacques Décary, Neil L.King, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: 1894 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 juin 1953, Tome 85, N° S3 Exercer l'industrie de la construction sous le nom de \"La Compagnie de Constructions Idéales Inc.\" \u2014 \"Ideal Constructions Company Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1755 Boulevard Morgan, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Lake Access Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-cinq avril 1953, constituant, en corporation: Hercule Décary, avocat, Lorenzo Décary, industriel, de Dorval, Lionel Crevier, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Construire des maisons d'habitation, sous le nom de \"Lake Access Enterprises Ltd.\", avec un capital de 820,000, divisé en 2,000 actions communes d'une valeur au pair de 810.chacune.Le siège social de la compagnie sera à Dorval, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Langlois et Rivard Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du premier mai 1953,-constituant en corporation: Lucien Bernier, comptable agréé, Gilles Trahan, étudiant, Leopold Lavignc, huissier, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les fonctions et commerce de courtiers en assurances et le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Langlois et Rivard Limitée\", avec un capital de 810,000, divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le premier mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.To carry on the business of building, under the name of \"La Compagnie de Constructions Idéales Inc.\" \u2014 \"Ideal Constructions Company Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1755 Morgan Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-fifth day of April, 1953.L.DÉSILETS.34950 Deputy Attorney General.Lake Access Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richclièrc, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q., 1941, bearing date the twenty-fifth day of April, 1953, incorporating: Hercule Décary, advocate, Lorenzo Décary, industrialist of Dorval, Lionel Crevier, advocate, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes : To build dwelling houses under the name of \"Lake Access Enterprises Ltd\", with a capital stock of $20,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the companu will be at Dorval, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-fifth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.Langlois et Rivard Limitée Notice is hereby given that under Part Iîof the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q.1941, bearing date the first day of May 1953, incorporating: Lucien Bernier, chartered accountant, Gilles Trahan, student, Leopold Lavignc, bailiff, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as, and carry on the business of insurance brokers, and deal in real estate, under the name of \"Langlois et Rivard Limitée\", with a capital of $10,000, divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the first day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.L'Association des Citoyens de Bordeaux Inc.L'Association des Citoyens de Bordeaux Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de Notice is hereby given that under Part III of la troisième partie de la Loi des compagnies de the Quebec Companies' Act, letters patent have Québec, il a été accordé par le Licutcnant-gou- been issued by the Lieutenant-Governor of the verneur de la province de Québec, représenté par Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chelière, in conformity with section 2, chapter chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-first en date du vingt et un avril 1953, constituant-en day of April 1953, to incorporate as a corpora-corporation sans capital-actions: Nicolas Vanier, tion without capital-stock: Nicolas Vanier, tavernier, Roger Gagnon, Victor St-Marseille, tavern-keeper, Roger Gagnon, Victor St-Mar-employés civils, tous des cité et district judiciaire seille, civil servants, all of the city and judicial de Montréal, pour les objets suivants: district of Montreal, for the following purposes: Développer et fortifier les relations sociales, To develop and strenghten social, athletic, sportives^ culturelles, éducatives entre les mem- cultural and educational relations between the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 6th, 1953, Vol.85, No.23 1895 bres.dc l'Association, sous le nom de \"L'Association des Citoyens de Bordeaux Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de SlO.OOa Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt et un avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Lee Holdings Corporation Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.Laltichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-cinquièmo jour d'avril 1953, constituant en corporation: Philip Meyerovitch, avocat et Conseil en Loi de Reine, Morris Shuter, gérant de bureau, tous deux de Montréal, Louis Feigenbaum, avocat, de Ville St-Laurent, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et disposer de valeurs, de toute firme, société bénévole, compagnie de fiducie, compagnie à fond social ou corporation, sous le nom de \"Lee Holdings Corporation\", avec un capital de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt cinquième jour d'avril 1953.-w* L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.members of the Association, under the name of \"L'Association des Citoyens de Bordeaux Inc.\".'The amount to which the value of immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 810,000.The head office of the corporation shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-first day of April 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.Lee Holdings Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1911, bearing date the twenty-fifth day of April, 1953, incorporating : Philip Meyerovitch, advocate and Queen's Counsel, Morris Shutcr, office manager, both of Montreal, Louis Feigenbaum, advocate, of Ville St.Laurent, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and dispose of securities, in any firm, voluntary association, trust, joint stock company, or corporation, under the name of \"Lee Holdings Corporation\", with a capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of the par value of S10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Les Breuvages Begin Ltée Begin Beverages Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1953, constituant en corporation: Joseph-Alexis Bégin, manufacturier, Jean-Charles Bégin, vendeur, Suzanne Bégin, comptable, tous des cité et district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer le commerce et/ou l'industrie de liqueurs douces, sous le nom de \"Les Breuvages Bégin Ltée\" \u2014 \"Bégin Beverages Ltd.\", avec un capital de» 850,000, divisé en 200 actions or-, dinaires de 8100 chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera aux Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuf avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Les Breuvages Bégin Ltée Bégin Beverages Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q.1941, bearing date the twenty-ninth day of April 1953, incorporating: Joseph-Alexis Begin, manufacturer, Jean-Charles Begin, salesman, Suzanne Begin, accountant, all of the city and judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on the soft drink business and/or industry thereof, under the name of \"Les Breuvages Bégin Ltée\" \u2014 \"Begin Beverages Ltd.\", with a capital stock of 850,000, divided into 200 common shares of S100 each and 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company shall be at Trois-Rivières judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-ninth day of April, 1953.x L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.L'Heureux et Dussault Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.Laltichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941 des lettres patentes, en date du quatre mai 1953, constituant en corporation: Léo L'Heureux, Léandre Dussault, mécaniciens en tuyauterie, et Simone Granger, ménagère, L'Heureux et Dussault Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with Section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourth day of May 1953, incorporating: Léo L'Heureux, Léandre Dussault, piping mechanics, and Simore Granger, housewife, wife, separate as to property, by 1896 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, G juin 1953, Tome 86, N° S3 -\u2022- épouse contractuellement séparée de biens de Raymond Brosseau, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de plombiers, sous le nom de \"L'Heureux et Dussault Limitée\", avec un capital de $60,000 divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatre mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.marriage contract, of Raymond Brosseau, and duly authorized by him for the purposes herein set forth, all of the city and juridial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as plumbers, under the name of \"L'Heureux et Dussault Limitée\", with a capital of $60,000 divided into 4,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the Company shall be at Montreal, judicial district of Alontreal.Dated at the office of the Attorney General, the fourth day of May 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.Lucky The Tailor Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelièrc, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-troisième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Fortunato Motafferi, Pascale Motafreri, tailleurs, Dame Marie Tozzi, épouse séparée de biens dudit Fortunato Motafferi, Dame Gertrude Perreault, épouse séparée de biens dudit Pascale Motafferi, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de tailleurs, sous le nom de \"Lucky The Tailor Inc.\", avec un capital de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1476 ouest, rue Ste-Catherine Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-troisième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Lucky The Tailor Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutcnant'Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.Laltichelière, in conformitv with section 2, chapter 270, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-third day of April, 1953, incorporating: Fortunato Motafferi, Pasquale Motafferi, tailors, Dame Marie Tozzi, wife separate as to property of the said Fortunato Motafferi, Dame Gertrude Pcrreault, wife separate as to property of the said Pasquale Motafferi, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of tailors, under the name of \"Lucky The Tailor Inc.\", with a capital stock of S40,000, divided into 200 shares of common stock with a par value of $100 each, and 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 1476 St.Catherine Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentv-third day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Marino Restaurant Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-deux avril 1953, constituant en corporation: Marino Bragoli, restaurateur, de Sillery Giovanni Bragoli, cuisinier, Henri-Paul Côté, comptable, tous deux de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer les opérations de restaurateurs, sous le nom de \"Marino Restaurant Ltée\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Marino Restaurant Liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richclière, in conformity with Section 2, Chapter 270, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-second day of April 1953, incorporating: Marino Bragoli, restaurant-keeper, of Sillcry, Giovanni Bragoli, cook, Henri-Paul Côté, accountant, both of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of restaurant keepers, under the name of \"Marino Restaurant Ltée\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company shall be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-second day of April 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.M.Létourneau, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.Laltichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-quatre avril 1953, constituant en M.Létourneau, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with Section 2, Chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-fourth day of April 1953, incorporating: Marcellin Létour- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 6th, 1963, Vol.86, No.23 1897 corporation: Marcellin Létourneau, commerçant, Dame Ernestine Létourneau, ménagère, épouse commune en biens de Marcellin Lérourneau, et Jacques Létourneau, étudiant, tous trois du Village de l'Islet Station, district judiciaire de Montmagny, pour les objets suivants: Faire le commerce de tous les matériaux de construction, sous le nom de \"M.Létourneau, Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à LTslet Station, district judiciaire de LTslet.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Moe Hcrscovitch & Sons Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.Laltichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-neuvième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Montgomery Hart Hcrscovitch, David William Hcrscovitch, Robert Harry Harte, agents d'assurance, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de courtiers d'assurance et agir comme agents d'assurance, sous le nom de \"Moe Herscovitch & Sons Inc.\", avec un capital de $50,000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 250 actions privilégiés d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-neuvième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Monarch Shoe Finishes & Supplies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chaj.\"-'» 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du trente avril 1953, constituant en corporation: Taschereau Forticr, Pierre Côté, avocats, Françoise Lapcrrière, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer généralement le commerce et l'industrie de manufacturier de produits chimiques, détergents, nettoyeurs, cire, poli, ainsi que tous accessoires et fournitures utilisés pour la fabri-.cation de chaussures et articles en cuir et plastic et autre matériel, sous le nom de \"Monarch Shoe Finishes & Supplies Ltd.\", avec un capital de $10,000, divisé en 200 actions de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le trente avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.New York Pleating Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a neau, merchant, Dame Ernestine Létourneau, housewife, wife common as to property of Marcellin Létourneau, and Jacques Létourneau, student, all three of the Village of LTslet Station, judicial district of Montmagny, for the following purposes: \u2022 To deal in all materials for construction, under the name of \"M.Létourneau, Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company shall be at LTslet Station, judicial district of LTslet.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-fourth day of April 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.Moe Herscovitch & Sons Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patenthave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.Laltichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-ninth day of April, incorporating: Montgomery Hart Herscovitch, David William Herscovitch, Robert Harry Harte, insurance agents, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of insurance brokers, and to act as insurance agents, under the name of \"Moe Herscovitch & Sons Inc.\", with a capital stock of $50,000, divided into 250 common shares of a par value of $100 each, and 250 preferred shares of à par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-ninth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Monarch Shoe Finishes & Supplies Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by M.C.La-Richelière, in conformity with section, 2 chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the thirtieth day of April, 1953, incorporating: Taschereau Fortier, Pierre Côté, advocates, Françoise La-perrière, secretary, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business and operate generally as a manufacturer of chemical products, detergents, cleansing products, wax, polish, as well as all accessories and findings utilized in the manufacture of shoes and leather articles and plastic and other material, under the name of \"Monarch Shoe Finishes & Supplies Ltd.\", with a capital stock of $10,000 divided into 200 shares of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April, 1953.n L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.New York Pleating Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 1898 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, G juin 1953, Tome S5, N° 23 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.Laltichelière.conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-cinq avril 1953, constituant en corporation: Hyman Davidson, manufacturier, Charles Brownstcin, avocat, et Mary Goldwater, secrétaire, épouse séparée de biens de Syndney Leon Goldwater, tous trois des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fabrication qui consiste à broder, plisser des tissus et à couvrir des boutons; exercer le commerce comme manufacturiers et marchands de vêtements, sous le nom de \"New York Pleating Inc.\", avec un capital de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI00 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de SlOOchacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Québec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276.R.S.Q.1941, bearing date the twenty-fifth day of April, 1953, incorporating: Hyman Davidson, manufacturer, Charles Brownstein, advocate, and Mary Goldwater, secretary, wife separate as to property of Sydney Ix*on Goldwater, all three of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a manufacturing business of embroidering, pleating and button covering; to carry on business as manufacturers, and dealers in clothing, under the name of \"New York Pleating Inc.\", with a capital stock of 840.000, divided into 200 common shares of the par value of 8100 each, and 200 preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fifth dav of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Pauzé & Chevrette, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1953, constituant en corporation: Jean St-Germain, avocat, de Westmount, Claire Goyer, sténographe, et Achille Raymond, comptable, tous deux de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer les commerces de bouchers-épiciers, de vendeurs de produits pharmaceutiques patentés, de marchandises sèches, sous le nom de \"Pauzé & Chevrette, Inc.\" avec un capital de S125.000, divisé en 400 actions communes de 8100 chacune et en 850 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Joliette, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Perfect Thread Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Riehelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-huit avril 1953, constituant en corporation: Joseph Shapiro, marchand, Leon Winer, marchand, Helen Wajsfus Shapiro, ménagère, épouse séparée de biens dudit Joseph Shapiro, Riva Shapiro Winer, ménagère, épouse séparée de biens dudit Leon Winer, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les ojets suivants: « Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et faire le commerce de coton, soie et autres fils, sous le nom de \"Perfect Thread Ço.Ltd.\", avec un capital de 825,000, divisé en 100 actions privilégiés de S100 chacune et 150 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 8031 avenue Byron, Ville St-Michel, district judiciaire de Montréal.Pauzé & Chevrette, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.Laltichelière, in conformity with Section 2, Chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventeenth day of April 1953, incorporating: Jean St-Ger-main, advocate, of Westmount, Claire Goyer, stenographer, and Achille Raymond, accountant, both of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of grocers and butchers, salesmen in patented pharmaceutical products, and dry goods, under the name of \"Pauzé & Chevrette, Inc.\".with a capital stock of $125,000, divided into 400 common shares of 8100 each, and 850 preferred shares of 8100 each.The head office of the company shall be at Joliette, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, the seventeenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.Perfect Thread Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.Laltichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-eighth day of April, 1953, incorporating: Joseph Shapiro, merchant, Leon Winer, merchant, Helen Wasjsfus Shapiro, housewife, wife separate as to property of the said Joseph Shapiro, Riva Shapiro Winer, house wife, wife separate as to property of said Léon Winer, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in cotton, silk and other thread, under the name of \"Perfect Thread Co.Ltd.\", with a capital stock of $25,000, divided into 100 preferred shares of $100 each, and 150 common shares of $100.each.The head office of the company will be at 8031 Byron Avenue, Ville St.Michel, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 6th, 1968, Vol.85, No.23 1899 Daté du bureau du Procureur général, le vingt- Dated at the office of the Attorney General huit avril 1953.this twenty-eighth day of April, 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 34950 L.DÉSILETS.34950-o Deputy Attorney General.Poly-Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.Laltichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date «lu vingt-sept avril 1953, constituant en corporation: Albert Boulet, C.A., Jacqueline Boulet, secrétaire-sténographe, de Québec, Émilien Si-mard, avocat, de Stc-Foy, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Conduire et poursuivre les affaires «le constructeurs et d'entrepreneurs, sous le nom de \"Poly-Construction Inc.\", avec un capital de $75,000, divisé en 35,000 actions ordinaires de $1 chacune, en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Thet-ford-Mines, district ju«liciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général le vingt-sept avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Poly-Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.Laltichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1911, bearing me Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.Laltichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-fifth day of April, 1953, incoqjora-ting: David Henry Holland, advocate, Cecil Bruce Cooke, secretary, Charles Eric Humphrey, Guy Ambrose Miller, bookkeepers, James Harold Stafford, clerk, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Vendôme Mines Limited\" (No Personal-Liability) with a capital stock of 83,500,000, divided into 3,500,000 shares of 81 each.The shareholders shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at the parish of Barraute, in the judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Wick Brothers Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, représenté par M.C.LaRichéliere, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, «les lettres patentes en date du vingt-cinquième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Half dan Arnold Wick, constructeur, Lillian Lyons, secrétaire, John Cerini, c.r., avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et négocier des propriétés immobilières et comme entrepreneurs généraux ou autrement, ériger des édifices et structures, sous le nom de \"Wick Brothers Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de là compagnie sera à 6527 «boulevard Translsland, en la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-cinquième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.Wick Brothers Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichéliere, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-fifth day of April, 1953, incorporating: Halfdan Arnold Wick, builder, Lillian Lyons, secretary, John Cerini, Q.C., advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with immoveable property and to erect as general contractors or otherwise, buildings and structures, under the name of \"Wick Brothers Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares with a par value of $10 each, and 2,000 preferred shares with a par value of $10 each.The head office of the company will be at 6572 Translsland Boulcvrad, in the city of Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Wynden Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, représenté par M.C.LaRichéliere, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du premier jour de mai 1953, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, avocat, Anne Zifkin, Sonya Schneyer, toutes deux secrétaires, de Montréal, Cyril E.Schwisberg, avocat, d'Oir-tremont, tous des cité et district judiciaire de Montreal, pour les objets suivants: Wynden Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.Laltichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the first day of May, 1953, incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Anne Zifkin, Sonya Schneyer, both secretaries, of Montreal, Cyril E.Schwisberg.advocate, of Outremont, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: 1904 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 juin 1953, Tome 85, N° 23 Exercer le commerce de peinturage à jets et cuite, d'articles en métal sous le nom de \"Wynden Industries Ltd.\", avec un capital de $50,000 divisé en* 250 actions ordinaires de $100 chacune et 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 66 est, rue Craig, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce premier jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.To carry on the business of spray painting and baking metal articles, under the name of \"Wynden Industries Ltd.\", with a capital stock of $50,000, divided into 250 common shares of $100 each, and 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 66 Craig St.East, city of Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this first day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Ameublements du Quebec Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRi-chelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 9 mai 1953, changeant le nom de la compagnie \"Acton Vale Furniture Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 14 février 1952, en celui de \"Ameublements du Québec Inc.\" Daté du bureau du Procureur général, le 9 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Ameublements du Québec Inc.Notice is given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with Section 2 of said Act, R.S.Q.1941, chapter 276 dated May 9th, 1953, changing the name of \"Acton Vale Furniture Limited, a company incorporated by letters patent dated February 14, 1952, under said Part I of the Quebec Companies' Act, into that of \"Ameublements du Québec Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, May 9th, 1 953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney General.City Tire Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 2 mai 1953, changeant le nom de la compagnie \"City Tire Shop, Limited\", constituée en corporation en vertu de la Eremière partie de la Loi des compagnies de Qué-ec, par lettres patentes datées du 2 décembre 1946, en celui de \"City Tire Company Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le 2 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34950 L.DÉSILETS.City Tire Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 2nd day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, changing the name of the company \"City Tire Shop, Limited\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies .Act, by letters patent dated December 2, 1946, to that of \"City Tire Company Limited\".Dated at the office of the Attorney General, the 2nd day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34950-o Deputy Attorney General.Foyer St-Henri Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de*Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du six mai 1953, à la corporation \"Hospice Saint-Henri Incorporée\", constituée en vertu des dispositions de la troisième partie de ladite loi, par lettres patentes en date du 5 juin 1929, et par lettres patentes supplémentaires en date du 22 avril 1930, a) changeant son nom ea celui de \"Foyer St-Henri Inc.\"; b) portant de $550,000 à $1,000,000 la valeur des immeubles que pourra détenir ladite corporation.Daté du bureau du Procureur général, le 6 mai 1952.L'Assistant-procureur général, 34950-o L.DÉSILETS.Foyer St-Henri Inc.m Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Companies' Act, supplementary lettersp atent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Provhice of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with Section 2 of said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, bearing date the sixth day of May 1953, to the \"Hospice Saint-Henri Incorporée\", a corporation incorporated under the provisions of Part III of said Act, by letters patent, dated June 5, 1929, and by supplementary letters patent dated April 22, 1930, a) changing its name to that of \"Foyer St-Henri Inc.\"; b) increasing from $550,-000 to $1,000,000 the value of immoveables which the said corporation may hold.Dated at the office of the Attorney General, the 6th of May 1953.L.DÉSILETS, 34950 Deputy Attorney Genera.l QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 6th, 1953, Vol.85, No.23 1905 Actions en séparation de biens AVIS LÉGAL Canada, province de Québec, District de Terrebonne, Cour Supérieure, N° 22,422.Dame Juliette Lavallée, de Saint-Eustache, district de Terrebonne, épouse commune en biens de Raoul Périllard, contracteur des mêmes lieux, demanderesse, vs Raoul Périllard, de Saint-Eustache, district de Terrebonne, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause, le 17 avril 1953.Saint-Eustache, le 27 mai 1953.Le Procureur de la demanderesse, 34951-0 J.-ALBERT PAQUIN, Canada, province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 333,960.Dame Germaine Sauriol, épouse commune en biens de Gaston Ampleman, gérant, domiciliée à l'Abord-à-Plouffe (149 Boul.Lévesque), district de Montréal, demanderesse vs Gaston Ampleman, susdit, défendeur.AVIS La demanderesse a formulé, ce jour, une action en séparation de biens contre le défendeur.Montréal, ce 28 mai 1953.L'avocat de la demanderesse, GÉRARD RAYMOND.276 ouest, rue St-Jacques, Montréal.34952-o Province de Québec, District de Joliette, Cour supérieure, N° 10927.Dame Rita Per-reault, de la municipalité du canton Chertsy, district de Joliette, épouse commune en biens de Pierre alias Léo Tremblay, commerçant, du même lieu, demanderesse, vs ledit Pierre alias Léo Tremblay, du même lieu, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 27 mai 1953.Joliette, le 30 mai 1953.\u2022 Le Procureur de la demanderesse, 34976-0 J.-A.BÉLANGER.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTER Numéro 663 Québec, le 29 mai 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Concernant la soustraction au jalonnement en claims miniers de certains terrains dans le canton de Holland, district électoral de Gaspé-Nord.Attendu que Trans-Gaspésien Aérien Limitée désire établir un terrain d'atterrissage dans le canton de Holland, district électoral de Gaspé-Nord, et demande à cette fin la soustraction au jalonnement en claims miniers de l'étendue couverte par ce terrain; Attendu que pour accélérer le développement minier et industriel de la Gaspésie, il y a lieu de se rendre à cette demande: Actions for separation as to property LEGAL NOTICE Canada, Province of Quebec, District of Terrebonne, Superior Court, No.22,422.Dame Juliette Lavallée, of Saint-Eustache, District of Terrebonne, wife common as to property of Raoul Périllard, contractor, of the same place, plaintiff, vs Raoul Périllard, of Saint-Eustache, district of Terrebonne, defendant.An action in separation as to property has been instituted in this cause, on April 17, 1953.Saint-Eustache, May 27, 1953.J.ALBERT PAQUIN, 34951 Attorney for Plaintiff.Canada, Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.333,960.Germaine Sauriol, wife common as to property of Gaston Ampleman, manager, of L'Abord-à-Plouffe (149 Boul.Levesque), district of Montreal, Plaintiff, vs Gaston Ampleman, aforesaid, Defendant.NOTICE Plaintiff has instituted, this day, an action in separation of property against the defendant.Montreal, May 28th 1953.GÉRARD RAYMOND, Attorney for Plaintiff.276, St.James St.W., Montreal.34952-0 Province of Quebec, District of Joliette, Superior Court, No.10927.Dame Rita Per-reault, of the municipality of township Chertsy, district of Joliette, wife, common as to property of Pierre alias Léo Tremblay, merchant, same place, plaintiff, vs the said Pierre alias Leo Tremblay, same place, defendant.An action for separation as to property has been taken in this case, the 27th of May 1953.Joliette, May 30th, 1953.J.A.BELANGER, 34976 Attorney for plaintiff.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 663 Quebec, May 29, 1953.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the withdrawal of staking out of mining claims on certain lands in the township of Holland, electoral district of Gaspé-North.Whereas Trans-Gaspesian Airline Limited is desirous of establishing a landing field in the township of Holland, electoral district of Gaspé-North, and for this purpose requests the withdrawal of the staking of mining claims on the area covered by said land: Whereas in order to hasten the mining and industrial development of Gaspé, it is expedient that this request be granted: 1906 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, G juin 1953, Tome 85, N° 23 Vu le paragraphe 7 de l'article 227 de la Loi des Mines, permettant au Lieutenant-gouverneur en conseil de réserver et soustraire au jalonnement en claims miniers les terrains qui, dans son opinion, peuvent être requis ou nécessaires pour les fins y spécifiées et autres fins.Il est oudonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre des Mines: Que le terrain décrit ci-après, situé dans le canton de Holland, district électoral de Gaspé-Nord, soit soustrait au jalonnement en claims miniers et réservé à la Couronne, à savoir: Un terrain borné à l'ouest par une ligne de direction nord astronomique, d'une longueur de deux (2) milles, partant de la plaque d'arpentage 141, placée sur le chemin de la rivière York, conduisant à la propriété de Gaspé Copper Mines Limited: au nord par une ligne de direction est astronomique, d'une longueur d'un mille et quart à l'est par une ligne de direction sud astronomique, d'une longueur de deux (2) milles: au sud par une ligne de direction ouest astronomique, d'une longueur d'un mille et quart (\\\\4), jusqu'à la plaque d'arpentage 141, point de départ.La superficie de ce terrain étant de deux milles et demi (2^) carrés.Et ce, à l'exception des.claims miniers présentement reconnus jusqu'à leur expiration ou leur renouvellement.(Signé) C.LARICHELIÈRE, 34974-0 Greffier Suppléant du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 642 Québec, le 29 mai 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conscil.Section \"A\" Concernant une modification au décret relatif aux employés de garage dans les cités de Québec et de Levis et les comtés de Québec, Lévis et Montmorency.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de proposer l'approbation d'une modification au décret numéro 765 du 13 mai 1938, amendé par les arrêtés numéros 1746, 1747 et 2778 des 2 septembre et 23 décembre 1938, 361, 544, 801 et 802 des 25 février, 29 mars et 8 mai 1939, 2099, 3324,' 4141 et 4199 des 27 mai, 11 septembre, 27 et 28 novembre 1940, 899 du 15 avril 1942, 3747 du 17 décembre 1943, 3231 du 17 août 1945, 2299 du 12 juin 1946, 492-A du 21 mars 1947, 483-A et 867-G des 7 avril et 9 juin 1948, 976-A du 31 août 1949, 108-A du 25 janvier 1950, 541-H et 1377-A des 30 mai et 6 décembre 1951 et 748-A du 27 juin 1952, relatif aux employés de garage dans les cités de Québec et de Lévis et les comtés de Québec, Lévis et Montmorency; Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 18 avril 1953; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; In view of paragraph 7, section 227, of the Quebec Mining Act, authorizing the Lieutenant-Governor in Council to reserve or withdraw the staking out of any land, which in his opinion, may be required or found necessary for the purposes herein specified, or for any other purposes.It is therefore ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Mines: That the land hereinafter described, situated in the township of Holland, electoral district of Gaspé-North.be withdrawn from the staking of mining claims and reserved in favour of the Crown, to wit: A piece of land bounded to the west by a line of direction north astronomic, two (2) miles in length, starting from surveyor's plate 141, located on the York river road, leading to Gaspé Copper Mines Limited: to the north by a line of direction east astronomic, one mile and a quarter {1)4.) in length: to the east by a line of direction south astronomic, two (2) miles in length: to the south by a line of direction west astronomic, one mile and a quarter (IÎ4) in length, extending to surveyor's plate 141, the starting point.The area of this land measuring two and a half (2,1^) square miles.And such, with the exception of mining claims presently recognized, up to the time of their expirv or renewal.(Signed) C.LARICHELIÈRE, 34974 Acting Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 642 Quebec, May 29, 1953.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"A\" Concerning an amendment of the decree relating to garage employees in the cities of Quebec, Levis and the counties of Quebec, Levis and Montmorency.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec.1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to amend the decree number 765 of May 13, 1938, as amended by Orders Nos.1746, 1747 and 2778 of September 2 and December 23, 1938, 361, 544.801 and 802 of Februarv 25, March 29 and May 8.1939, 2099, 3324, 4141 and 4199 of May 27, September 11, November 27 and 28, 1940, 899 of April 15, 1942, 3747 of December 17, 1943.3231 of August 17, 1945, 2299 of June 12, 1946, 492-A of March 21, 1947, 483-A and 867-G of April 7 and June 9, 1948, 976-A of August 31, 1949, 108-A of Januarv 25, 1950, and 541-H and 1377-A of May 30 and December 6, 1951, and 748-A of June 27, 1952, relating to garage employees in the cities of Quebec and Levis and the counties of Quebec, Levis and Montmorency; Whereas the said notice was published in the Quebec Official Gazette, issue of April 18, 1953; Whereas the objections thereto were duly considered, as required by the Act; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June Gth, 1953, Vol.85, No.23 1907 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'Hbnorable Premier Ministre, Que ledit décret, numéro 705, soit modifié comme suit : L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe \"a\" de l'article II: \"Sont également exempte de la présente juridiction, les établissements qui se spécialisent dans le lavage de voitures-automobiles selon le système à chaîne, à l'exclusion de toute autre activité visée par le présent décret.\" (Document \"A\" annexé à l'arrêté) C.LARICHELIÈRE, 34979-0 Greffier Suppléant du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL v CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 042 Québec, le 29 mai 1953.Présent: Le Licutenant-Gouvemcur-cn-Conscil.Section \"B\" Concernant des modifications au décret relatif aux manutenteurs de fret \u2014 navigation côtière et intérieure \u2014 Havre de Montréal.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 103 et amendements), le Comité conjoint de la navigation côtière et .intérieure du Port de Montréal, a présente au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier le décret numéro 686 du 18 mars 1943, amendés par les arrêtés numéros 421-Act 1132-E des 30 mars et 1er septembre 1948, 1050-C du 20 septembre 1950, 290-C du 22 mars 1951 et 438-B du 23 avril 1952, relatif aux manutenteurs de fret, navigation intérieure et côtière, dans le Havre de Montréal; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette Officielle de Québec, édition du 18 avril 1953; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: Que ledit décret, numéro 686, soit modifié comme suit: Les paragraphes \"a\", \"b\" et \"g\" de l'article IV sont remplacés par les suivantes: \"a) Tout travail exécuté entre 7.00 a.m.et 7.00 p.m.doit être rémunéré aux taux horaire d'un dollar et quarante-trois cents (81.43).\" / \"b) Tout travail exécuté entre 7.00 p.m.et 7.00 a.m.doit être rémunéré au taux horaire d'un dollar et soixante-ct-huit cents ($1.08).\" \"g) Les manutenteurs de fret préposés à la conduite de machines à empiler ou de tracteurs doivent ercevoir $0.10 de.plus par heure que le taux de salaire régulier payé aux manutenteurs de fret.\" (Document \"B\" annexé à l'arrêté) Le Greffier Suppléant du Conseil Exécutif.34979-q C.LARICHELIÈRE, ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 642 Québec, le 29 mai 1953.It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable Prime Minister, That the said decree, number 765, be amended as follows: The following paragraph is added to subsection \"a\" of section II: \"Establishments specializing in car washing by the belt system (usually called 10-minute washing), excluding all other activities governed by the present decree, shall also be exempt from the'present jurisdiction.\" (Document \"A\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, 34979-0 Acting Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 042 Quebec, May 29, 1953.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part\"B\" j Concerning amendments of the decree relating to the freight handlers of the Port of Montreal \u2014 inland and coastal navigation.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), the Joint Committee of Inland and Coastal Navigation of the Port of Montreal has submitted to the Minister of Labour a petition to amend the decree number 686 of March 18,1943, as amended by Orders 421-A and 1132-E of March 30 and September 1, 1948, 1056-C of September 20, 1950, 290-C of March 22, 1951 and 438-B of April 23, 1952, relating to the freight handlers of the Port of Montreal \u2014 inland and coastal navigation; Whereas the said petition was published in the Quebec Official Gazette, issue of April 18, 1953; Whereas no objection was made against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable Prime Minister, That the said decree; number GS6, be amended as follows; Subsections \"a\", \"6\" and of section IV are replaced by the following: \"a) All time worked between 7.00 a.m.and 7.00 p.m., shall be remunerated at the hourly rate of one dollar and forty-three cents ($1.43)\".\"t>) All time worked between 7.00 p.m.and 7.00 a.m.shall be remunerated at the hourly rate of one dollar and sixty-eight cents ($1.68)\".\"g) Designated freight handlers required to operate piling machines or tractors shall be paid 80.10 per hour in addition to the regular rate of pay of freight handlers.\" (Document \"B\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, 34979-0 Acting clerck of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 642 Quebec, May 29, 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil Present: The Lieutenant Governor in Council. 1908 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 juin 1953, Tome 85, N° S3 Section \"C\" Concernant la prolongation du décret relatif à l'industrie de la construction dans la région de Québec.Il est ordonné, sur la propostions de l'honorable Premier Ministre: Que le décret numéro 1730 du 23 octobre 1947 et amendements, relatif à l'industrie de la construction dans la région de Québec, soit prolongé jusqu'au 1er juillet 1953.(Document \"C\" annexé à l'arrêté) Le Greffier Suppléant du Conseil Exécutif, 34979'o C.LARICHELIÈRE.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTD7 Numéro 642 Québec, le 29 mai 1952.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"G\" Concernant la prolongation du droit de prélèvement du comité aconjoint des métiers de la construction de Québec.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre du Travail: Que le droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Québec, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 438-D du 23 avril 1952, soit prolongé jusqu'au 1er juillet 1953, aux mêmes taux et conditions.Le Greffier suppléant du Conseil Exécutif.34979-0 C.LARICHELIÈRE, ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 643 Québec, le 29 mai 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Concernant une convention collective de travail relative à l'industrie de la fourrure, section du détail, région de Montréal.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes ci-après mentionnées ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: D'une part: L'Association des Marchands détaillants du Canada \u2014 Québec, Inc., Section de la Fourrure; et, d'autre part: L'Union Nationale du Vêtement, Inc., Section de la Fourrure; pour les employeurs et les salariés de l'industrie et des métiers visés, suivant les conditions décrites dans la Gazette officielle de Québec, édition du 18 avril 1953; Attendu que les dispositions de ladite convention ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l'établissement des conditions de travail dans les métiers et l'indus- Part \"C\" Concerning an extension of the decree relating to the construction industry in the district of Quebec.It is ordained, on the recommendation of the Honourable Prime Minister.That the decree No.1730 of October 23, 1947, as amended, relating to the construction industry in the district of Quebec, be extended until July 1st, 1953.(Document \"C\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, 34979-0 Acting Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 642 Quebec, May 29, 1953.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"0\" Concerning an extension of the right to levy _ of the Joint Committee of the Construction Industry, Quebec.It is ordered, on the recommendation of the Honourable Prime Minister, That the right to levy of the Joint Committee of the Construction Industry of Quebec, authorized by a by-law approved by Order in Council No.438-D of April 23, 1952, be extended until July 1st, 1953, with the same rate and conditions.C.LARICHELIÈRE, 34979-0 Acting Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 643 Quebec, May 29, 1953.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning a collective labour agreement; relating to the fur industry, retail section, district of Montreal.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties hereafter mentioned have submitted to the Minister of Labour a petition to render obligatory the collective labour agreement entered into between: On the one part: The Retail Merchands Association of Canada-Quebec, Inc., Fur Section; And, on the other part: \"L'Union nationale du Vêtement Inc., Section de la Fourrure\", for the employers and the employees of the industry and the trades concerned, according to the conditions described in the Quebec Official Gazette of April 18, 1953; Whereas the provisions of the said agreement have acquired a preponderent significance and importance for the establishing of working conditions in the trades and the industry concerned QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June Gtk, 1953, Vol.85, No.-28 1909 trie visés et dans la juridiction territoriale indiquée dans ladite requête: Attendu que les prescriptions de la Loi ont été dûment suivies en ce qui touche la publication des avis; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre ladite requête; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: Que ladite requête soit acceptée conformément aux dispositions de ladite Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements) avec, toutefois, les nouvelles dispositions suivantes tenant lieu des conditions décrites dans la Gazelle officielle de Québec, édition du 18 avril 1953; 1.Définitions: à) Dans le décret, le terme \"maître-fourreur\"ou \"détaillant en fourrure\" désigne toute personne dont l'occupation consiste dans la fabrication et la vente à l'unité des manteaux et autres articles en fourrure, qui fabrique elle-même, dans son atelier, lesdits articles pour les revendre directement au client ou au consommateur et qui exécute pour le compte de ses clients, des réparations sur tout article en fourrure.6) Dans le décret, le mot \"apprenti\" désigne un salarié qui, comme employé dans l'établissement d'un maître-fourreur, n'a pas terminé effectivement la période prévue dans les différents articles du décret ayant trait à l'apprentissage; l'employeur peut lui demander n'importe quelle sorte de travail, pourvu qu'il ne soit pas habituellement employé à des travaux d'une classe supérieure à celle pour laquelle il est payé.Tout apprenti employé plus de la moitié de son temps chaque semaine à des travaux d'une classe supérieure à la sienne, doit être rémunéré pour chaque heure au taux de la classe dans laquelle il travaille.L'apprenti doit avoir seize (16) ans révolus.c) Pour devenir un \"coupeur qualifié\", le coupeur doit avoir travaillé effectivement au moins trois (3) ans dans ce genre de travail.Si, après cette période d'apprentissage, l'apprenti n'a pas acquis l'adresse requise pour devenir un coupeur qualifié, il peut demander au Comité paritaire la permission de continuer ce travail pendant douze mois additionnels au salaire dont le Comité paritaire décidera.IL Juridiction: a) Juridiction professionnelle: 1.Les dispositions du décret s'appliquent aux établissements représentés par la partie contractante de première part, aux établissements particuliers signataires de la convention, ainsi qu'à tous les détaillants en fourrure faisant affaires dans la juridiction territoriale décrite au paragraphe \"b\" du présent article, et à tous les salariés ouvriers qualifiés et apprentis, a leur emploi.2.Le décret ne s'applique pas à l'industrie de la garniture en fourrure et de la teinture des fourrures; il ne couvre pas non plus les établissements s'occupant des travaux appartenant à ladite industrie.Proviso: Au cas de difficulté au sujet de l'assujettissement d'un détaillant en fourrure qui fait en même temps le commerce du gros et qui aurait signé les deux conventions, l'officier de conciliation du Ministère du Travail a le droit de déterminer sous quel décret tombe ledit marchand détaillant.b) Juridiction territoriale: La juridiction territoriale du décret comprend l'Ile de Montréal et le territoire compris dans un rayon de cinquante (50) milles de ses limites, à vol d'oiseau.III.Durée du travail: a) La durée hebdomadaire du travail est de quarante (40) heures, distribuées selon les besoins de l'employeur entre and in*\"the territorial jurisdiction indicated in the said petition; Whereas the provisions of the Act were duly observed as regards the publication of notices; 7 Whereas no objection was raised against the said petition; It is ordered, therefore, on the recommendation of the Honourable Prime Minister, That the said petition be accepted in pursuance of the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments) with, however, the following new provisions to be substituted for the conditions described in the Quebec Official Gazette, issue of April IS, 1953: I.Definitions: a) In the decree, the term \"master-furrier\" or \"fur retailer\" means any person whose occupation consists in producing and selling, by unit, fur coats and any other fur articles; in making himself, in his shop, the said articles to be sold directly to the customer or consumer; in making for customers the repairing of any fur articles.b) In the decree, the word \"apprentice\" means an employee who, as employee in the establishment of a master furrier, has not actually terminated the period established under the various sections of the decree concerning apprenticeship; the employer may request from him the execution of any kind of work provided he is not habitually employed in operations of a higher class than that for which he is paid.Any apprentice employed more than half the working time each week in operations of a higher class than his, shall receive the hourly rate of the class in which he is working.The apprentice must be at least sixteen (16) years old.c) To become a \"qualified cutter\", the cutter must have effectively worked at least three (3) years in such operation.If, after the said apprenticeship period, the apprentice has not acquired the skill required to become a qualified cutter, he may request from the Parity Committee an authorization to carry on such work during twelve additional months at a rate of pay determined by the said Committee.II.Jurisdiction: a) Professional jurisdiction: 1.The provisions of the decree apply to establishments represented by the contracting party\" of the first part, to private concerns that signed the agreement and to all retail fur merchants operating within the territorial jurisdiction described in subsection \"b\" of the present section and to all employees, qualified workers and apprentices in their employ.2.The decree does not apply to the fur trimming and dyeing industry; neither does it apply to establishments doing work connected with the said industry.Proviso: Should there be difficulties as to the subjection of a retail merchant engaged at the same time, in wholesale business and having signed both agreements, the conciliation officer of the Department of Labour shall have the right to determine the decree by which the said retail merchant shall be covered.b) Territoriahjurisdiction: The territorial jurisdiction of the decree comprises the Island of Montreal and a radius of fifty (50) miles from its limits, in straight line.IH.Duration of labour: a) The weekly duration of labour shall be of forty (40) hours, distributed according to the needs of the em- 1910 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, (i juin 1053, Tome 85, N° 23 8.00 a.m.et 0.00 p.m., à l'exception du samedi et du dimanche.Le samedi, le travail doit se terminer à 1.00 p.m.Pour faire travailler ses salariés le samedi après 1.00 p.m., un employeur doit en donner avis par écrit au comité paritaire.Tout travail exécuté en dehors de ces heures de travail est considéré comme travail supplémentaire et doit être rémunéré à raison de salaire et demi, excepté durant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, où il est permis à l'employeur de faire travailler ses salariés une semaine de quarante-quatre (44) heures, au taux régulier, en deçà des heures indiquées plus haut.Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, un salarié qui se rapporte en retard à son travail par sa faute doit compléter le nombre régulier d'heures de travail pour ce jour, avant d'être rémunéré à raison de temps et demi.Les employeurs peuvent cependant, par tolérance spéciale, garder à leur service, le samedi avant-midi, pour les mois de janvier et février, une finisseuse à temps régulier.La semaine régulière de cette employée ne doit pas, cependant, dépasser quarante-quatre (44) heures).b) Cependant, les employeurs faisant affaires en dehors de l'Ile de Moutréal, ont droit à la semaine de travail de quarante-quatre (44) heures au taux régulier mais demeurent assujettis à toutes les autres dispositions du présent article, en ce qui concerne les heures de travail de leurs salariés.Durant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, il est permis auxdits employeurs de faire travailler leurs salariés une semaine de quarante-huit (48) heures, aux taux réguliers.IV.Jours de fûtes rémunérés: Tous les salariés doivent être rémunérés les jours de fêtes suivants: le Premier de l'An, le Vendredi-Saint, l'Ascension, la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Travail, la Toussaint, l'Immaculée Conception et la Noël.Un autre jour peut être substitué au Vendredi-Saint, à la Saint-Jean-Baptiste et à la fête du Travail pourvu que l'employeur obtienne l'autorisation écrite du Comité paritaire à cette fin.Cependant, pour avoir droit à ce congé payé, les salariés doivent avoir travaillé au moins une partie de la semaine où ledit congé tombe, et dans ce cas, le salarié doit recevoir pour ce jour une rémunération proportionnée à la durée de son travail pour une semaine de quarante (40) heures.Le salaire dû par l'employeur à ses salariés pour ces jours de fête est celui que les salariés auraient reçu si l'atelier avait été ouvert ce jour-là et si les salariés y avaient travaillé les heures régulières réglementaires.Cette clause ne joue pas, cependant, si les fêtes plus haut décrites tombent un dimanche.Quand le jour de Noël et.le Premier de l'An tombent un dimanche, le lundi suivant est chômé et payé.Si le salarié travaille un des jours de fêtes ci-haut désignés, il doit recevoir le taux régulier de salaire, plus salaire et demi, mais en aucun cas,' un employeur ne peut obliger son salarié à travailler ces jours-là.Si l'établissement ferme ses portes pendant la semaine où un congé tombe, les salariés doivent recevoir leur salaire complet pour ce jour de fête.V.Définitions spéciales: a) Pour chaque opération, le nombre des salariés de la classe \"A\" doit représenter au moins 50% des préposés à telle dite opération.Si l'employeur devient obligé de réduire son personnel, il est quand même ployer, between 8.00 a.m.and 6.00 p.m., excepting Saturday and Sunday.On Saturday, work shall cease at 1.00 p.m.For all time worked on Saturday after 1.00 p.m.the employer shall notify the Parity Committee, in writing.All time worked beyond these hours is considered as overtime and paid for at the rate of time and one half, with the exception of the months of September, October, November and December during which it is permitted for an employer to have his employees work a forty-four (44) hour week at the regular rate of pay within the hours above mentioned.Notwithstanding the pro visions of the foregoing paragraph, an employee late to work by his own fault shall complete the regular number of working hours for that day before being entitled to the time-and-a-half rate.The employers may, however, by special tolerance, keep a female finisher to work on Saturday morning, for the months of January and February, at straight time.The regular week of such employee shall not, however, exceed forty-four (44) hours.b) However, the employers doing business outside the Island of Montreal, are entitled to the 44-hour week at the regular rates but shall remain subject to all other provisions of the present section, inasmuch as working hours of their employees are concerned.During the months of September, October, November and December, it is permitted for said employers to have their employees work a forty-eight (4S) hour week, at regular rates of pay.IV.Remuneration on holidays: All employees shall receive remuneration for the following holidays: New Year's Day, Good Friday, Ascension Day, St.John the Baptist Day, Labour Day, All Saints' Day, Immaculate Conception Day and Christmas Day.Another day may be substituted for Good Friday, St.John the Baptist Day and Labour Day provided the employer obtains written authorization from the Parity Committee to that effect.However, to be entitled to this paid holiday, the employees must have worked at least part of the week where the said holiday occurs and, in this case, the employee shall receive, for this day, a remuneration based on the proportion of his hours of work with respect to a forty-hour week.The wages owed by the employer to his employees in regard of these holidays shall be that which the employees would have received if the establishment had been open that day and if the employees had worked the regular hours.This clause does not apply, however, when the holidays above described fall on Sunday.When Christmas and New Year's Day fall on Sunday, the following Monday shall be kept as a holiday.Should an employee work one of the said holidays, he shall receive the regular rates of wages plus time and a half but an employer shall never compel his employee to work on such days.Should the establishment close in the course of the week wherein there is a holiday, the employees shall receive their complete wages such holiday.V.Special definitions: a) For each operation, the number of employees of class A shall represent at least 50% of the number of employees for said operation.Should the employer be forced to reduce his personnel, he shall have to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June Gtk, 1953, Vol 85, No.28 1911 tenu
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.