Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 20 (no 25)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1953-06-20, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 85, N° 25 2029 Vol.85, No.25 i Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 20 juin 1953 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour .publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1953.Québec, le 8 juin 1953.' L'Imprimeur de la Reine.35004-24-12-o RÊDEMPTI PARADIS.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, June 20th, 1953 RECEIPT OF ADVERTISING COPD2S Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1953.Quebec, this 8th, of June 1953.REDEMPTI PARADIS, 35004-24-12-o Queen's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before Autorisé comme envoi postal \"de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter.0240 2030 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 juin 195S, Tome 85, N\" 25 insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine: mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine* avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc: Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre: le deuxième à celui de l'édition de la Gazctte-pour la première insertion: le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie Sue la matière n'est ni de notre composition ni e notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, REDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.33898 \u20141-52 Lettres patentes Abitibi Diamond Drilling Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, ila été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt mai 1953, constituant en corporation: Lorenzo Gauthier, photographe, Gaston Duval, comptable, Armand Gilbert, notaire, tous de the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order ot the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of-republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc: First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number: the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion: the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but once are followed only by our document number.REDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.33898 \u20141-52 Letters Patent Abitibi Diamond Drilling Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twentieth day of May, 1953, incorporating: Lorenzo Gauthier, photographer, Gaston Duval, accountant, Armand Gilbert, notary, all of Val QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1953, Vol.86, No.25 2031 Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Abitibi Diamond Drilling Limited\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de $50,000, divisé en 50,000 actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Ace Realty Services Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du douze mai 1953, constituant en corporation: Henri Messier, Claude Beauregard, notaires, Roger Éthier, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme agent d'immeubles et courtier en immeuble, et faire les affaires générales d'immeuble, sous le nom de \"Ace Realty Services Incorporated\", avec un capital de 840,000, divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Ajax Distributing of Quebec Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du onzième jour de mai 1953, constituant en corporation: Alcide Grenon, comptable, Bella Bugeaud, sténographe, tous deux de la cité de Montréal, Paul-H.Lcvesque, avocat, de ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de machines automatiques de toutes sortes servant à vendre, dispenser et distribuer des marchandises, ainsi que l'outillage s'y rapportant, sous le nom de \"Ajax Distributing of Quebec Corp.\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce onzième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Amos Lumber Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La- d'Or, in the judicial district of Abitibi, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Abitibi Diamond Drilling Limited\" (No Personal Liability), with a capital stock of $50,000, divided into 50,000 shares of $1 each.The shareholders will incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Val d'Or, in the judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Ace Realty Services Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with Section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twelfth day of May 1953.incorporating: Henri Messier, Claude Beauregard, notaries, Roger Ethier, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as agent and broker in real estate, and the business thereof generally, under the name of \"Ace Realty Services Incorporated\", with a capital stock of S40,000, divided into 400 snares of S100 each.The head office of the company shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twelfth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Ajax Distributing of Quebec Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eleventh day of May, 1953, incorporating: Alcide Grenon, accountant, Bella Bugeaud, stenographer, both of the city of Montreal, Paul-H.Levesque, advocate, of the town of Mount-Royal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in vending, dispensing and distributing machines of all kinds and equipment for same, under the name of \"Ajax Distributing of Quebec Corp.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eleventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Amos Lumber Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La- 2032 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SO juin 1953, Tome 86, N° S5 Richelière, conformément si l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du treize mai 1953, constituant en corporation: Germain Samson, industriel, Marie-Jeanne Ro-chon-Samson, ménagère, épouse séparée de biens dudit Germain Samson, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Maurice Lcblond, commis, tous d'Amos, district judiciaire d'Abi-tibi, pour les objets suivants: Exercer toutes opérations forestières, et le commerce de bois, sous le nom de \"Amos Lumber Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune et en 300 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Amos, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général le treize mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Awnair Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du septième jour de mai 1953, constituant en corporation: Raymond Lebœuf, avocat, Gisèle Behocaray, secrétaire, tous deux des cité et-district judiciaire de Montréal, et Myrto Brasseur, secrétaire, de St-Eustache, district judiciaire de Terrebonne, pour Ise objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et faire le commerce d'auvents, outils et outillage d'auvents, sous le nom de \"Awnair Company Limited\", avec un capital de $12,000, divisé en 12,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Axai Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date d.u neuvième jour de mai 1953, costituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat c.r., Ethel Yus-sem, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, Theodore H.Shapiro, avocat, de ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et faire le commerce de valeurs, sous le nom de \"Axai Corp.\", Le capital-actions de la compagnie est divisé en 100 actions sans valeur nominale ou au pair et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie exercera ses affaires sera de $500.Les actions sans valeur au pair seront émises et réparties au prix de $5 l'action.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciairede Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce neuvième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirteenth day of May 1953, incorporating: Germain Samson, industrialist, Marie-Jeanne Rochon-Samson, housewife, wife separate as to property of said Germain Samson ami duly authorized by him for these purposes, Maurice Leblond, clerk, all of Amos, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To carry on all forestry operations and the lumber business, under the name of \"Amos Lumber Ltd.\", with a capital fo $40,000, divided into 1,000 preferred shares of $10 each and 300 common shares of $100 each.The head office of the company shall be at Amos, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General the thirteenth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Awnair Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebc.c represented by Mr.C.La-Richclièie t in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventh day cf May, 1953, incorporating: Raymond Leboeuf advocate, Gisèle Behocaray, secretary, both of the city and judicial district of Montreal, and Myrto Brasseur, secretary, of St-Eustache, in the judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in awning, awning tools and equipments, under the name of \"Awnair Company Limited\", with a capital stock of $12,000, divided into 12,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Axal Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.G.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the ninth day of May, 1953, incorporating: Joseph Shapiro, advocate, Q.C., Ethel Yussem, secretary, both of the city of Montreal, Theodore H.Shapiro, advocate, of the town of Mount Royal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with securities, under the name of \"Axal Corp.\", The capital stock of the Company is 100 shares having no nominal or par value and the amount of capital with which the company will carry on business will be $500.The no par value shares shall be issued and allotted at a price of $5 per share.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1953, Vol 86, No.25 2033 Beaulicu Transport Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quinze mai 1953, constituant en corporation: Auguste Désilets, Roger Deshaies, avocats, Rolande Lacroix, fille majeure, sténographe, tous de Grand'Mère, district judicière des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exploiter une entreprise générale de camionnage et de transport de marchandises et d'effets de toute nature, sous le nom de \"Beaulieu Transport Limitée\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Grand-Mère, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le quinze mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Britex Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du treizième jour de mai 1953, constituant en corporation: Hilliard Ginsberg, Abraham Jacob Rosenstein, avocat, Aima Agnes Boa, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judi ciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à Manufacturer et faire le commerce de vêtements tricotés et de sport, sous le nom de \"Britex Ltd.\", avec un capital de $99,900, divisé en 499 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce treizième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Beaulieu Transport Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day of May 1953, incorporating: Auguste Désilets, Roger Deshaies, advocates, Rolande Lacroix, spinster, stenographer, all of Grand'Mère, judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on the business generally, of transporting and carrying merchandise and articles of all kinds, under the name of \"Beaulieu Transport Limitée', with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company shall be at Grand-Mère judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General the fifteenth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Britex Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirteenth day of May, 1953, incorporating: Hilliard Ginsberg, Abraham Jacob Rosenstein, advocates, Alma Agnes Boa, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in knitted clothing and sportswear, under the name of \"Britex Ltd.\", with a capital stock of $99,900, divided into 499 common shares of a par value of $100 each, and 500 preferred shares of a par value of $100.each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Brookdalc Farm Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du neuf mai 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Hibert Vi-pomd, entrepreneur, de Hull-Sud, James Wylie Thomson, secrétaire, de Buckingham, Howard Felton Harris, fermier, de Gatineau, Donald F.McKechnie, comptable public certifié, d'Ottawa, Allen Carey, agent, de Campbell's Bay, Athol Dale, Hillard I.Hobbs, marchands, de Shaw-ville, Albert Shouldice, conducteur de bestiaux, d'Aylmer Est, Foster Faris, fermier, d'Aylmer Est, Reginald Clerke, fermier, de Wakefield, pour les objets suivants: Fournir une maison chrétienne protestante inter-confessionnelle pour les enfants orphelins, nécessiteux ou négligés, sous le nom de \"Brook-dale Farm Inc.\" Brookdale Farm Inc.Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the ninth day of May, 1953, incorporating without share capital: Hibert Vipond, contractor, of South Hull, James Wylie Thomson, secretary, of Buckingham, Howard Felton Harris, farmer, of Gatineau, Donald F.McKechnie, certified public accountant, of Ottawa, Allen Carey, agent, of Campbell's Bay, Athol Dale, Hillard I.Hobbs, merchants, of Shawville, Albert Shouldice, drover, of Aylmer East, Foster Faris, farmer, of Aylmer East, Reginald Clarke, farmer, of Wakefield, for the following purposes: To privide an interdenominational Protestant Christian Home for orphaned, needy or neglected children, under the name of \"Brookdale Farm Inc.\" 2034 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 juin 1958, Tome 85, N° 25 Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Farm Point, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 \u2022 L.DÉSILETS.Building Entreprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quinze mai 1953, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat, c.r., Ethel Yussem, secrétaire, Jean McFarlane, dactylo, filles majeures, de la cité de Montréal, et Theodore H.Shapiro, avocat, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements et d'immeubles, sous le nom de \"Building Enterprises Inc.\", avec un capital de $50,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Farm Point, judicial district of Hull.Dated at the office of the Attorney General this ninth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Building Entreprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of May, 1953, incorporating: Joseph Shapiro, advocate, Q.C., Ethel Yussem, secretary, Jean McFarlane, typist, spinsters, of the city of Montreal, and Theodore H.Shapiro, advocate, of the town of Mount Royal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment and real estate company, under the name of \"Building Enterprises Inc.\", with a capityd stock of $50,000.divided into 200 common shares of $100 each, and 300 preferred shares of S100 each.» The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Canadian Fents Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quinzième jour de mai 1953, constituant en corporation: Max Isidore Sigler, Moses Hyman Myerson, avocats, Isidore Black, vendeur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, vendre des marchandises telles que textiles, rebuts de moulin, résidus de marchandises en soie, coton et laine, sous le nom de \"Canadian Fents Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège socia1 de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quinzième jour de mai 1953.L'Assistant-procu re u r \"général, 35036 L.DÉSILETS.Charlie's News Stand Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du treize mai 1953, constituant en corporation: Louis Paradis, avocat, Armand Vigneault, agent d'assurances, Francis H.Vigneault, gérant de la Caisse Populaire, tous de Sept-Iles, district judiciaire de Saguenay, pour les objets suivants: Canadian Fents Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRL- -chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of May 1953, incorporating: Max Isidore Sigler, Moses Hyman Myerson, advocates, Isidore Black, salesman, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To buy, sell such merchandises textiles, mill-ends, remnants of silk, cotton and woollen gooas, under the name of \"Canadian Fents Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of #100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial dLtrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Charlie's News Stand Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of May, 1953, incorporating: Louis Paradis, lawyer, Armand Vigneault, insurance agent, Francis-H.Vigneault, manager of the Caisse Populaire, all of the Sept-Iles, judicial district of Saguenay, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1953, Vol.86, No.26 2035 Exercer le commerce d'un restaurant, sous le nom de \"Charlie's News Stand Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 150 actions privilégiées de $100 chacune et 250 actions ordinaires\" de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sept-Iles, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Citadel Automobiles Limitée Citadel Automobile Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du neuf mai 1953, constituant en corporation: Armand Asselin, ' marchand, Hélène Lachance, ménagère, célibataire, Dame Marie-Paule Lachance Asselin, épouse séparée de biens de Armand Asselin, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de tous les effets, articles, marchandises, outils, équipement, se rattachant à l'industrie et au commerce de l'automobile, sous le nom de \"Citadel Automobiles Limitée\" \u2014 \"Citadel Automobile Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le neuf mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSLLETS.Conseil d'Expansion Economique, Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du douze mai 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Jacques Viau, avocat, c.r., de la cité de Lachine, Jacqueline Matte, et Paula Boisvert, sténographes, toutes deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Grouper les hommes d'affaires canadiens-français en vue de constituer un organisme de propagande ayant pour but de faire connaître et de stimuler la participation des Canadiens-français à la vie commerciale, industrielle et financière, sous le nom de \"Conseil d'Expansion Économique, Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est, de $100,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.' Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Cowansville Juvénile Recreation Club Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouver- To carry on the business of a restaurant, under the name of \"Charlie's News Stand Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 150 preferred shares of $100 each and 250 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Sept-Iles, in the judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS.35036-o Deputy Attorney General.Citadel Automobiles Limitée Citadel Automobile Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the ninth day of May 1953, incorporating: Armand Asselin, merchant, Hélène Lachance, housekeeper, spinster, Dame Marie-Paule Lachance-Asselin, wife separate as to property of Armand Asselin, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in all accessories, articles, merchandise, tools, and equipment pertaining to the automobile industry and business thereof, under the name of \"Citadel Automobiles Limitée\" \u2014 \"Citadel Automobile Limited\", with a capital of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company shall be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, the ninth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Conseil d'Expansion Économique, Inc.Notice is hereby given that under the provisions of Part HI of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twelfth day of May 1953, to incorporate as a corporation without capital-stock: Jacques Viau, advocate, Q.C., of the city of Lachine, Jacqueline Matte, and Paula Boisvert, stenographers, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To group French-Canadian business men together in order to form an organization of propaganda for the purpose of making French-Canadians better known in the field of industry, commerce and finance, and as a stimulus for their participation therein, under the name of \"Conseil d'Expansion Économique, Inc.\".The amount to which the value of immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twelfth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Cowansville Juvénile Recreation Club Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies] Act, letters patent have been issued by the Lieute- 2036 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 juin 1953, Tome 86, N° 25 neur de la province de Québec, représenté par M.C.Larichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quinze mai 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Majorie Bertha Massey, secrétaire, ménagère, épouse séparée de biens de A.-B.Massey et dûment autorisée par lui, Grant Reid Paterson, inspecteur de textiles, Gordon Terrill Robertson, commis, Toralf Joli an n ess en Sandstad, contremaître, Robert Colin Jarvis, gérant de banque, Penelope Mary Deirdre Bieber, ménagère, épouse séparée de biens de W.H.Bieber et dûment autosirée par lui, Lloyd Newton Sully, comptable, Albert Gagnon, ébéniste, tous de Cowansville, John Norris Wood, principal d'un \"high school\", Guy Baxter Cousens, teinturier de textiles, tous deux de Sweetsburg, tous du district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: La promotion du bien-être physique et moral de la jeunesse de la ville de Cowansville et du district aux moyens de sports organisés et d'autres genres de divertissements convenables, sous le nom de \"Cowansville Juvenile Recreation Club.\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $100,000.Le siège social de la corporation sera à Cowansville, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.nant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of May, 1953, incorporating without share capital: Marjorie Bertha Massey, secretary, housewife, wife separated as to property from A.-B.Massey and duly authorized by him, Grant Reid Paterson, textile inspector, Gordon Tcrrill Robertson, clerk, Toralf Johanncsscn Sandstad, foreman, Roberr Colin Jarvis, bank manager.Penelope Mary Deirdre Bieber, housewife, wife separate as to property from W.-H.Bieber and duly authorized by him, Lloyd Newton Sully, accountant, Albert Gagnon, furniture maker, all of Cowansville, John Norris Wood, high school principal,.Guy Baxter Cousens, textile dyeing, both of Sweetsburg, all of the judicial district of Bedford, for the following purposes: The promotion of the physical and moral well-being of the youth of the town of Cowansville and district through organized sports and other forms of suitable entertainment, under the name of \"Cowansville Juvenile Recreation Club.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at Cowansville, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Dore Lingerie Mfg.Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quinze mai 1953, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry Lyon Aronovitch, avocats, et Freda Pomerance, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements, sous le nom de \"Dore Lingerie Mfg.Co.Inc.\", avec un capital de $120,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.E.C.Shatilla & Sons Ltd.E.C.Shatilla & Fils Liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-neuf mai 1953, constituant en corporation: Charles H.Desjardins, Edward G.Tannage, avocats, Jeannette Desjardins, sténographe, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce de grossiste, négociants à forfait, importer et exporter des menus objets, jouets, quincaillerie, produits textiles, bibelots, Dore Lingerie Mfg.Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of May, 1953, incorporating: Samuel Chait, Harry Lyon Aronovitch, advocates, and Freda Pomerance, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, under the name of \"Dore Lingerie Mfg.Co.Inc.\", with a capital stock of $120,000, divided into 200 common shares of the par value of $100 each, and 1,000 preferred shares of the par valeu of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of May, 1953.L.DÊSLLETS, 35036-o Deputy Attorney General.E.C.Shatilla & Sons Ltd.E.C.Shatilla & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies! Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the nineteenth day of May, 1953, incorporating: Charles-H.Desjar-dins, Edward G.Tannage, advocates, Jeannette Desjardins, stenographer, unmarried, all of the city and judicial district of Montréal, for the following purposes: To carry on a wholesale, jobbing, import and export business of samll-wares, toys, hardware, textiles, notions, dry goods, china glass-ware QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1958, Vol.85, No.25 2037 marchandises sèches, porcelaine, verrerie et des marchandises négociées dans des magasins d'articles divers, sous le nom de \"E.-C.Shatilla & Sons Ltd.\", \u2014 \"E.-C.Shatilla & Fils Ltée\", avec un capital de 840,000, divisé en 250 actions ordinaires de S100 chacune et 150 actions privilégiées de SlOO'chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.-DÉSILETS.Empire Entreprises Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-neuf mai 1953, constituant en corporation: Philip Fischel Vineberg, avocat, de la cité de Westmount, Jack Lightstone; avocat, Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger des affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Empire Enterprises Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Gem Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du douzième jour de mai 1953, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Ethel Yussem, secrétaire, fille majeure, tous deux de la cité de Montréal, Théodore H.Shapiro, avocat, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et de placements, sous le nom de \"Gem Investment Corp.\", avec un capital de $30,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce douzième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Giant Fruit Distributors Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du vingt mai 1953, constituant en corporation: and merchandise for the variety store trades, under the name of \"E.-C.Shatilla & Sons Ltd.\" \u2014 \"E.-C.Shatilla & Fils Ltée\", with a capital stock of $40,000, divided into 250 common shares of $100 each and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS.35036-o Deputy Attorney General.Empire Entreprises Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the nineteenth day of May, 1953, incorporating: Philip Fischel Vineberg, advocate, of the city of Westmount, Jack Lightstone, advocate, Yvonne Bélanger, secretary, spinster, both of the City of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as bulders, and general contractors, under the name of \"Empire Enterprises Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 2,000 preferred shares of the par value of $10 each and 2,000 common shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of May, 1953.L.DÉSDLETS, 35036-o Deputy Attorney General.Gem Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twelfth day of May, 1953, incorporating: Joseph Shapiro, advocate and Queens' Counsel, Ethel Yussem, secretary, spinster, both of the city of Montreal, Theodore H.Shapiro, advocate, of the town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of \"Gem Investment Corp.\", with a capital stock of $30,000, divided into 300 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1953.L.DÉSILETS.35036-o Deputy Attorney General.Giant Fruit Distributors Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twentieth day of May, 1953, incorporating : Marcel Deslauriers, 2038 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 juin 1953, Tome 85, N° 25 Marcel Deslauriers, acheteur, Denis-Paul Deslauriers, vendeur, René Deslauriers, marchand, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour lés objets suivants: Exercer le commerce de marchands de fruits et de légumes, sous le nom de \"Giant Fruit Distributors Inc.\", avec un capital de 840,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o - L.DÉSILETS.purchaser, Denis-Paul Deslauricrs, salesman, René Deslauricrs, merchant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as fruit and vegetable merchant*, under the name of \"Giant Fruit Distributors Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twentieth .day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Granby Furniture Manufacturing Inc.Granby Furniture Manufacturing Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière.conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du huit mai 1953, constituant en corporation: Charlie Duguay, Roland Mathieu, Jean-Marc Brunet, machinistes, tous de Granby, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce des meubles meublants, sous le nom de \"Granby Furniture Manufacturing Inc.\", avec un capital de $50,000, divise en 100 actions privilégiées de $100 chacune et en 40,000 actions communes de $1.chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général le huit mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Hillsdale Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt mai 1953, constituant en corporation: Nathan Levitsky, Solomon Weber, avocats.Rose Markis, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre le commerce de construction, sous le nom de \"Hillsdale Construction Co.Ltd.\", avec un capital de $75,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière,in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eighth day of May 1953, incorporating: Charlie Duguay, Roland Mathieu, Jean-Marc Brunct, machinist, all of Granby, judicial district \"of Beford, for the following purposes: To manufacture and deal in household furniture, under the name of \"Granby Furniture Manufacturing Inc.\", with a capital of $50,000, divided into 100 preferred shares of $100 each, and 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company shall be at Granby; judicial district of Bodford.Dated at the office of the Attorney General the eighth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Hillsdale Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twentieth day of May, 1953, incorporating: Nathan Levitsky, Solomon Weber, advocates, Rose Markis, secretary, fille majeure, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To engage in the construction business, under the name of \"Hillsdale Construction Co.Ltd.\", with a capital stock of $75,000, divided into 400 common shares of a par value of $100 each, and 350 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.I.G.O.Fenton Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, mai 1953, constituant en corporation: Cyril E.Schwisberg, avocat, d'Outremont, Sonya Schne-yer, Anne Zifkin, secrétaires, filles majeures, I.G.O.Fenton Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirteenth day of May, 1953, incorporating: Cyril E.Schwisberg, advocate, of Outremont, Sonya Schneyer, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1958, Vol 85, No.25 2039 toutes deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour Ise objets suivants : Exploiter le commerce de la construction, sous le nom de \"I.G.O.Fenton Construction Ltd.\", avec un capital de $100,000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce treizième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Ingrid Michèle Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du treizième jour de mai 1953, constituant en corporation: Clarence Reuben Gross, avocat, Evelyn Shane, secrétaire, Sarah Miller, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de robes, vêtements de sport, lingerie, accessoires pour dames et articles vestimentaires pour enfants, et bébés sous le nom de \"Ingrid Michèle inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune, et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce treizième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS, Insurance Exchange Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du quinze mai 1953, constituant en corporation: James Evelyn Mitchell, avocat et conseil en loi de la Reine, John Fitzwilliam Stairs, Patrick Emmet Kierans, Albert Bronson Culver, John Brooke Claxton avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Insurance Exchange Realties Ltd.\", avec un capital de $50,000, divisé en 1,000 actions de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Ivanhoe Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes-en date du douzième jour de mai 1953, constituant en Anne Zifkin, secretaries, spinsters, both of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of construction, under the name of \"L G.O.Fenton Construction Ltd.\", with a capital stock of $100,000, divided into 500 common shares of $100 each and 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.\u2022 Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Ingrid Michèle Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiceh-liere, in conformity with section 2, chapiter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirteenth day of May, 1953, incorporating: Clarence Reuben Gross, advocate, Evelyn Shane, secretary, Sarah Miller, stenographer, all of the city and judicial distfict of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in ladies dresses, and infants' wear, under the name of \"Ingrid Michèle Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 300 preferred shares of the par value of $100 each, and 1,000 common shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Insurance Exchange Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day of May, 1953, incorporating: James Evelyn Mitchell, advocate and Queen's Counsel, John Fitzwilliam Stairs, Patrick Emmet Kierans, Albert Bronson Culver, John Brooke Claxton, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Insurance Exchange Realties Ltd.\", with a capital stock of $50,000, The head office of the company will be at the city of Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Ivanhoe Corp.Notice is hereby given that under Part I o the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twelfth day of May, 1953 incorporating: Joseph Shapiro, 2040 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 juin 1953, Tome 85, N° 25 corporation: Joseph Shapiro, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Ethel Yussem, secrétaire, Jean McFarlane, filles majeures, dactylo, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et de placements, sous le nom de \"Ivan-hoe Corp.\", avec un capital de $750.000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune, 5,000 actions privilégiées de $100 chacune et 2.000 actions, série A, d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce douzième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.J.Caplan & Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du quinze mai 1953, constituant en corporation* Michael Garber, avocat et conseil en loi de la Reine, de la cité de Wcstmount, Jacob Harold Blumenstein, avocat, Irene Rubin, fille majeure, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le négoce ou le commerce de toutes sortes de tissus et produits de tissus, sous le nom de \"J.Caplan & Co.Ltd.\", avec un capital de $125,000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et 750 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.J.H.Marron\\ & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix-neuf mai 1953, constituant en corporation J.-Hervé Marcoux, Jules Marcoux, J.-Paul Mar-coux, entrepreneurs de pompes funèbres, tous de Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs de pompes funèbres, sous le nom de \"J.H.Marcoux & Fils Ltée\", avec un capital de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Victoria-bille, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mai 1953.L.Assistant-procureur général, * 5036-o L.DÉSILETS.J.L.Beaudet Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La- advocate and Queen's Counsel, Ethel Yussem, secretary, Jean McFarlane, spinsters, typist, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of \"Ivan-hoe Corp.\", with a capital stock of $750,000, divided into 500 common shares of $100each, 5,000 preferred shares of $100 each and 2,000 Class À shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twelfth dav of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.J.Caplan & Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day of May, 1953, incorporating: Michael Garber, advocate and Queen's Counsel, in the City of Wcstmount, Jacob Harold Blumenstein, advocate, Irene Rubin, fille majeure, secretary, both of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in or with all kinds of fabrics and fabric products, under the name of \"J.Caplan & Co.Ltd.\", with a capital stock of $125,000, divided into 500 common shares of $100 each, and 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.J.II.Marcoux & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with Section 2, Chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the nineteenth day of May 1953, incorporating: J.-Hervé Marcoux, Jules Marcoux, J.-Paul Marcoux, undertakers, all of Victoriaville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To carry on business as an undertaker, under the name of \"J.H.Marcoux & Fils Ltée\", with a capital of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company shall be at Victoriaville, judicial\" district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, the nineteenth dav of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.J.L.Beaudet Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1953, Vol 85, No.25 2041 Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix-neuf mai 1953, constituant en corporation: J.-Lucien Beaudet, agent manufacturier, Dame B.Vermette Beaudet, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit J.-Lucien Beaudet, Pauline Gobeil, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: , Exercer sous toutes ses formes le commerce de vente et installation d'appreils de chauffage, plomberie, ventilation, air conditionné et élec tricité, sous le nom de \"J.L.Beaudet Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 400 Boulevard Charest, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le dix-neuf mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.J.R.Duquette Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du neuf mai 1953, constituant en corporation: J.-Rojand Duquette, marchand, Béatrice Beau-champ-Duquette, ménagère, J.-Jules Beauchamp vendeur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de tabac, cigarettes, bonbons et autres marchandises, sous le nom de \"J.R.Duquette Incorporée\", avec un capital de $75,000, divisé en 750 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le neuf mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the nineteenth day of May 1953, incorporating: J.Lucien Beaudet, manufacturer's agent, Dame B.Vermette Beaudet, housewife, wife separate as to property of the said J.Lucien Beaudet, Pauline Gobeil, secretary, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business, in all its branches, of selling heating, plumbing, ventilation air-conditioning and electrical equipment and the installation thereof, under the name of \"J.L.Beaudet Inc.\", with a capital of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each, and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company shall' be at 400 Boulevard Charest, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General the nineteenth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.J.R.Duquette Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the ninth day of May 1953, incorporating: J.-Roland Duquette, merchant, Beatrice Beauchamp-Duquette, housewife, J.-Jules Beauchamp, salesman, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in tabacco, cigarettes, candies and other merchandise, under the name of \"J.R.Duquette Incorporée\", with a capital of $75,-000, divided into 750 shares of $100 each.The head office of the company shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General the ninth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Kon Frères Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, cofnormément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du douzième jour de mai 1953, constituant en corporation: George Kon, marchand, Abraham Kon, Leo Kon, fourreurs, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et passer des contrats d'articles vestimentaires de toutes sortes, sous le nom de \"Kon Frères Ltée\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce douzième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Kon Frcres Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twelfth day of May, 1953, incorporating: George Kon, merchant, Abraham Kon, Leo Kon, furriers, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and contracting of wearing apparel of all kinds, under the name of \"Kon Frères Ltée\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of a par value of $100 each and 200 preferred shares of a par value of $100 each.i The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 3503G-o Deputy Attorney General. 2042 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 juin 1953, Tome 85, N° 25 La Compagnie de Placements Hudson Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt mai 1953, constituant en corporation: C.-Antoine Geoffrion, Luc Parent, avocats, delà cité de Montréal, et Guillaume Geoffrion, avocat, de la cité de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants; Exercer les opérations d'une compagnie de placements, sous le nom de \"La Compagnie de Placements Hudson Limitée\", avec un capital de $600,000, divisé en 300,000 actions privilégiées et en 300,000 actoins ordinaires, toutes de la valeur au pair de $1.chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.La Corporation du Service Social du Diocëse de Saint-Jérôme Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du treize mai 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Maurice Girard, ingénieur industriel, Flavius Leclerc, médecin, Georges Dunnigan, camionneur, René-W.Hébert, assistant-gérant,, de Saint Jérôme, André Fauteux, avocat, Guy Blanchard, notaire, de Ste-Thérèse, Roger Lagarde, avocat, Lorenzo Turcotte, médecin, de Lachute, et Dorius Lé-pine, entrepreneur général, de Brownsburg, tous du district de Terrebonne, pour les objets suivants: Secourir les familles en détresse, les enfants naturels, les personnes inadaptées, difficiles, irrégulières et délaissées, sous le nom de \"La Corporation du Service Social du Diocèse de Saint-Jérômé\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général le treize mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Leeds Manufacturing Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R-Qm 1941, des lettres patentes en date du douzième jour de mai 1953, constituant en corporation: Percy George Abelson, manufacturier, Harold S.Freeman, Abraham H.J.Zait-lin, avocats Hyman Freeman, vendeur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers et marchands de vêtements et articles vestimen- La Compagnie de Placements Hudson Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with Section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twentieth day of May 1953, incorporating: C.Antoine Geoffrion, Luc Parent, advocates, of the city of Montreal, and Guillaume Geoffrion, advocate of the city of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate as an investment company, under the name of \"La Compagnie de Placements Hudson Limitée\", with a capital of $600,000, divided into 300k000 preferred shares and 300,000 common shares, all of a par value of $1.each.The head office of the company shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twentieth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.La Corporation du Service Social du Diocese de Saint-Jerome Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., bearing date the thirteenth day of May-1953, to incorporate as a corporation without capital-stock: Maurice Girard, industrial engineer, Flavius Leclerc, physician, Georges Dunnigan, carrier, René-W.Hébert, assistant-manager, of Saint-Jérôme, André Fauteux, advocate, Guy Blanchard, notary, of Ste-Thérèse, Roger Lagarde, advocate, Lorenzo Turcotte, physician, of Lachute, and Dorius Lépine, general contractor, of Brownsburg, all of the judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To assist families in distress, illegitimate children unadapted, difficult, backward and neglected persons, under the name of \"La Corporation du Service Social du Diocèse de Saint-Jérôme\".The amount to which the value of immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation shall be at Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, the thirteenth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Leeds Manufacturing Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twelfth day of May, 1953, incorporating: Percy George Abelson, manufacturer, Harold S.Feeman, Abraham H.J.Zaitlin, advocates, Hyman Freeman, salesman, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers in clothing and wearing apparel, under QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1953, Vol.86, No.26 2043 taires, sous le nom de \"Leeds Manufacturing Co.\", avec un capital de $75,000, divisé en 500 actions privilégiées de $100 chacune et 250 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce douzième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Lee Tea Room Inc.Avis est donné qu'en vertu de la paremière partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-troisième jour de mai 1953, constituant en corporation : Allan Lee, vendeur, Steve Tene, chaudronnier, tous deux de la cité de New York, état de New York, un des états unis d'Amérique, et Suzanne Nicholas, fille majeure, de la cité de Boston, état de Massachusetts, un des états unis d'Amérique, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à exploiter des salles de thé, restaurants et en général exercer les commerces de pourvoyeurs et confiseurs, sous le nom de \"Lee Tea Room Inc.\", avec un capital de $5,000, divisé en 1000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1510 rue Stanley, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-troisième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Leonard Auto Supply Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Riche'ièie, conformément à l'artic'e 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des iettres patentes en date du douzième jour de mai 1953, constituant en corporation: Leonard Cohen, marchand, David Lack, avocat, Pearl Auerbach, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exeivar le commerce qui.consiste à manufacturer et faire le commerce d'outillage, essences, pièces, dispositifs et accessoires de toutes sorte:, et descriptions, servant aux véhicules-moteurs et utilisés dans les machines motorisées, sous le nom de \"Leonard Auto Supply Company\", avec un capital de $50,000, divisé en 200 actions ordinaires de $50 chacune et 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté-du bureau du Procureur général, ce douzième jour de mai 1953.L'AssLtant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Les Aqueducs Coderre,- Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date the name of \"Leeds Manufacturing Co.\" with a capital stock of $75,000, divided into* 500 preferred shares of $100 each, and 250 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twelfth day of May, 1953.L.DÉSILETS 35026-o Deputy Attorney General.Lee Tea Room Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-third day of May, 1953, incorporating : Allan Lee, salesman, Steve Tene, coppersmith, both of the city of New York, in the State of New York, one of the United States of America, and Suzanne Nicholas, spinster, of the city of Boston, in the State of Massachusetts, one of the United States of America, for the following purposes: To carry on the business of operating tea rooms, restaurants and generally engage in the the catering and confectionery business, under the name of \"Lee Tea Room Inc.\", with a capital stock of $5,000, divided into 1000 common shares of a par value of $5 each.The head office of the company will be at 1510 Stanley Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney Genera'.Leonard Auto Supply Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformitv with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twelfth day of May, 1953, incorporating: Leonard Cohen, merchant, David Lack, advocate, Pearl Auerbach, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in motor vehicle and power machine equipment, fuels, parts, supplies and accessories of every kind and description, under the name of \"Leonard Auto Supply Company\", with a capital stock of $50,000, divided into 200 common shares of $50 each, and 400 preferred shares at a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Les Aqueducs Coderre, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the nineteenth 2044 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SO juin 1953, Tome 85, N° S5 du dix-ucnf mai 1953, constituant en corporation: Paul-Edouard Dessane, comptable, Irène Bégin, sténographe, Jacques Guérin, étudiant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un ou des aqueducts, des puits artésiens, des usines de pompage et de filtration, sous le nom de \"Les Aqueducs Coderre, Limitée\", avec un capital de $100,000, divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-neuf mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Les Autobus Deshaics Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du douze mai 1953, constituant en corporation: Alphonse Deshaies, propriétaire d'autobus, Gaston Deshaies, et Louis-Gilles Deshaies, chauffeurs d'autobus, tous de Deschaillons, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Opérer un ou des services d'autobus, sous le nom de \"Les Autobus Deshaies Ltée\", avec un capital de $90,000, divisé en 450 actions privilégiées de $100 chacune, et en 450 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Deschaillons, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procuteur général le douze mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.day of May 1953, incorporating: Paul-Edouard Dessane, accountant, Irène Begin, stenographer, Jacques Guérin, student, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate one or more aqueducts, artesian wells, pumping and filtration works, under the name of \"Les Aqueducs Coderre, Limitée\", with a capital stock of $100,000 divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General-the nineteenth dav of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Les Autobus Deshaies Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patenthave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by.Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twelfth day of May 1953, incorporating: Alphonse Deshaies, owner of autobus, Gaston Deshaies and Louis-Gilles Deshaies, bus drivers, all of Deschaillons, judicial district of Quebec, for the following purr pose* : To operate one or more bus services, under the name of \"Les Autobus Deshaies Ltée\", with a capital of $90,000, divided into 450 preferred shares of $100 each, and 450 common shares of $100 each.The head office of the company shall be at Deschaillons, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General the twelfth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35.036 Deputy Attorney General.Magil Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du dix-neuf mai 1953, constituant en corporation: Philip Fischel Vineberg, avocat, de la cité de Westmount, \"Jack Lightstone, avocat, Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger des affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Magil Construction Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Magil Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the nineteenth day of May.1953, incorporating: Philip Fischel Vineberg, advocate, of the city of Westmount, Jack Lightstone, advocate, Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, both of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders, and general contractors, under the name of \"Magil Construction Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 2,000 preferred shares of the par value of $10.each, and 2,000 common shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of May, 1953.L.\" DÉSILETS, 35036-o Deputy'Attorney General.Maurice Cossette Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date Maurice Cossette Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with Section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eleventh day of May QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1953, Vol.86, No.26 2045 du onze mai 1953, constituant en corporation: Maurice Cossette, agent distributeur, Marie-Anne Desgagnés-Cossette, seorétaire, épouse dudit Maurice Cossette, tous deux de Val d'Or, Rémi Cossette, gérant, d'Amos, tous du district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'agent licencié pour la vente et la distribution en gros de la bière, du porter et des boissons alcooliques, sous le nom de \"Maurice Cossette Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1953.35036-o L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.1953, incorporating: Maurice Cossette, agent-distributor, Marie-Anne Desgagnés-Cossette, secretary, wife of said Maurice Cossette, both of Val d'Or, Rémi Cossette, manager, of Amos, all of the judicial district of Abitibi, for the following purposes: To carry on a business as a licensed agent for the sale and wholesale distribution of beer, porter, and alcoholic beverages, under the name of Maurice Cossette Inc.\", with a capital stock of $40,-000, divided into 400 common shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company shall be at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, the eleventh day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attoreny General.Mercantile Realty Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du douzième jour de mai 1953, constituant en corporation: Claude Sartoris Riohardson, conseil en Loi de la Reine, William Patrick Creagh, étudiant en droit, et David Henry Holland, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie d'immeubles et de développement, sous le nom de \"Mercantile Realty Company\", avec un capital de $500,000, divisé en 5,000 actions d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce douzième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Mercantile Realty Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twelfth day of May, 1953, incorporating : Claude Sartoris Richardson, Queen's counsel, William Patrick Creagh, law clerk, and David Henry Holland, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a general real estate and development business, under the name of \"Mercantile Realty Company\", with a capital stock of $500,-000, divided into 5,000 shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twelfth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35026-o Deputy Attorney General.Metropolitan Television Service Limited Metropolitan Television Service Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément a l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix-neuf mai 1953, constituant en corporation: Louis Sicotte, marchand, de ville LeMoyne, Raymond Lafortune, radio-technicien, de Montréal, Jacques Massue, comptable, de Saint-Lambert, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Faire affaires comme locateurs, agents à commission et marchands d'appreils de télévision et de radio, sous le nom de \"Metropolitan Television Service Limited\", avec' un capital de $40,000, divisé en 800 actions de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à ville LeMoyne, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-neuf mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the nineteenth day of May 1953, incorporating: Louis Sicotte, merchant, of ville Lemoyne, Raymond Lafortune, radio-technician, of Montreal, Jacques Massue, accountant, of Saint-Lambert, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as lesaois, commission-agents and dealers in television and radio sets, under the name of \"Metropolitan Television Service Limited\", with a capital stock of $40,-000, divided into 800 shares of $50 each.The head office of the company shall be at ville Lemoyne, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General the nineteenth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Moquin & Vida Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La- Moquin & Vida Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La- 2046 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SO juin 1958, Tome 85, N° S6 Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date de dix-neuvième jour de mai 1953, constituant en corporation: Jack Lightstrone, avocat, Yvonne Bélanger, Roslyn Soloway, filles majeures, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme entrepreneurs, constructeurs, sous le nom de \"Moquin & Vida Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera si Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-neuvième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Morley Hodgins Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-neuvième jour de mai 1953, constituant en corporation: Morley E.Hodgins, manufacturier de bois de construction, R.Ray, Shep-pard, vendeur, Gordon T.Paul, courtier d'assurances, tous du village de Shawville, district judiciaire de Pontiac, pour les objets suivante: Exercer le commerce d'exploitation forestière et celui qui consiste à préparer le bois de construction, sous le nom de \"Morley Hodgins Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera au village de Shawville, district judiciaire de Pontiac.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-neuvième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Mount Royal Furniture & Television Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du seizième jour de mai 1953, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, avocat, Anne Zifkin, Sonya Schneyer, secrétaires, filles majeures, tous trois de Montréal, et Cyril E.Schwis-berg, avocat, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands de dispositifs ou accessoires électriques, meubles, articles de ménage, sous le nom de \"Mount Royal Furniture & Television Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 204 est, rue Mont-Royal, cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the nineteenth day of May, 1953, incorporating: Jack Lightstone, advocate, Yvonne Bélsmger, Roslyn Solo-way, filles majeures, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To .carry on business as contractors, builders, under the name of \"Moquin & Vida Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of the par value of $100 each and 200 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this nineteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Morley Hodgins Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the nineteenth day of May, 1953, incorporating: Morley E.Hodgins, lumber manufacturer, R.Ray, Shep-pard, salesman, Gordon T.Paul, insurance Broker, all of the village of Shawville, judicial district of Pontiac, for the following purposes: To carry on the business of lumbering and lumber, manufacturing, under the name of \"Morley Hodgins Limited\", with a capital stock of $40,000, dividedinto 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at the Village of Shawville, in the judicial district of Pontiac.Dated at the office of the Attorney General this nineteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Mount Royal Furniture & Television Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the sixteenth day of May, 1953, incorporating : Samuel Green- i blatt, advocate, Anne Zifkin, Sonya Schneyer, secretaries, filles majeures, all three of Montreal, and Cyril E.Schwisberg, advocate, of Outre-mont, all in the judicial district of Montreal, for % the following purposes: To carry on business as dealers in electric appliances or supplies, furniture, household ar-ricles, under the naine of \"Mount Royal Fur- * niture & Television Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 250 common shares of $100 each and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 204 Mount Royal St.East, city of Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixteenth day of May, 1953.* L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1958, Vol.85, No.25 2047 Namur Realties Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à Particle 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quinzième jour de mai 1953, constituant en j corporation: John Fitzwilliam Stairs, Patrick Emmet Kierans, Albert Bronson Culver, avocats, tous .des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et exploiter une certaine propriété immobilière, sous le nom de \"Namur Realties Limited\", avec un capital de $75,000, divisé en 750 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quinzième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 36036 L.DÉSILETS.New Way Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix-neuf mai 1953, constituant en corporation: J.-Eloi Gervais, Damase Brissette, avocats, de Longueuil, Jacqueline Laliberté, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer tous et aucun des commerce* comme entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"New Way Construction Co.Ltd.\", avec un capital de $10,000, divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-neuf mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Namur Realties Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day of May, 1953, incorporating: John Fitswilliam Stairs, Patrick Emmet Kierans, Albert Bronson Culver, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with a certain immoveable property, under the name of \"Namur Realties Limited\", with a capital stock of $75,000, divided into 750 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifteenth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.New Way Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the nineteenth day of May 1953, incorporating: J.-Eloi Gervais, Damase Brissette, advocates, of Longueuil, Jacqueline Laliberté, secretary, spinster, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: ,To carry on the business of General contractors and builders in all its branches, under the name of \"New Way Construction Co.Ltd.\", with a capital stock of $10,000, divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General the nineteenth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Norema Construction Ltée (Ltd.) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du premier mai 1953, constituant en corporation: Henri Beaulieu, de la cité de Montréal, Jean Beaulieu, de la cité d'Outremont, et Jean Cas-grain, de la cité de Westmount, tous avocats et conseils en loi de la Reine, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires en général comme constructeurs, sous le nom de \"Norema Construction Ltée (Ltd.)\", avec un capital de $210,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune, et en 2,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera situé au numéro 98, rue des Sulpiciens, municipalité de l'Epiphanie, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général le premier mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Norema Construction Ltée (Ltd.) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the first day of May 1953, incorporating: Henri Beaulieu, of the city of Montreal, Jean Beaulieu, of the city of Outremont, and Jean Casgrain, of the city of Westmount, all lawyers and Queen's Counsel, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business, generally, as builders, under the name of \"Norema Construction Ltée (Ltd.)\", with a capital of $210,000 divided into 100 common shares of -$100 each, and 2,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company shall be at number 98 des Sulpiciens Street, municipality of l'Epiphanie, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General the first day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General. 2048 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 juin 1953, Tome 86, N° 25 Odéon Appareils Électriques et Meubles Ltée Odéon Appareils Électriques et Meubles Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du onzième jour de mai 1953, constituant en corporation: Lillian Golden, épouse séparée de biens de Joseph Golden et dûment autorisée par lui, Hyman Friedman, gérant, Reuben Zemel, étudiant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'articles vestimentaires, fournitures, fourrures, meubles, produits en bois, accessoires et outillage électriques, sous le nom de \"Odeon Appareils Électriques et Meubles Ltée\", avec un capital de «20,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce onzième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Quebec Acceptance Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du sept mai 1953, constituant en corporation: Jean Léonard, agent d'affaires, Charles-Edouard Léonard, M.D., et Madeleine Léonard, secrétaire tous trois de la cité de Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Faire des prêts d'argent, sous le nom de \"Que-bec Acceptance Corporation\", avec un capital de $225,000, divisé en 750 actions ordinaires d'une valeur de $100 chacune et en 1,500 actions privilégiées d'une valeur de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général le sept mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Regal Bakery Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la premièrep ar-tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quinzième jour de mai 1953, constituant en corporation: Chaskiel Michel Zylberberg, marchand, Gregory Charlap, Max Slapack, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de pain, gâteaux, pâtisseries et tous articles d'alimentation produits par la cuisson, sous le nom \"Regal Bakery Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quinzième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patenthave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eleventh day of May, 1953, incorporating: Lillian Golden, wife separate as to property of Joseph Golden and duly authorized by him, Hyman Friedman, manager, Reuben Zemel, student, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal with clothing apparel furnishings, fur, furniture, wood products, electrical appliances and equipment, under the name of \"Odéon Appareils Électriques et Meubles Ltée\", with a capital stock of $20,000, divided into 100 common shares of $100 each, and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the AttorneyGeneral this eleventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Quebec Acceptance Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patenthave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventh day of May 1953, incorporating: Jean Léonard, business agent, Charles-Edouard Léonard, M.D., and Madeleine Léonard, secretary, all three of the city of Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To act as money lenders, under the name of \"Quebec Acceptance Corporation\", with a capital of $225,000, divided into 750 common shares of a value of $100 each and 1,500 preferred shares o£ a value of $100 each.The head office of the company shall be at Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General the seventh day of May 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Regal Bakery Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of May 1953, incorporating: Chaskiel Michel Zylberberg, merchant, Gregory Charlap, Max Slapack, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in bread, cakes, pastry and all articles of food produced by baking, under the name of \"Regal Bakery Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1953, Vol.85, No.26 2049 Slipper Specialties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt et unième jour de mai 1953, constituant en corporation: David Bellam, marchand et manufacturier, d'Outremont, Sam Bellam, marchand, Alexander Bellam, contremaître, tous deux de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de produits faits de cuir, sous le nom de \"Slipper Specialties Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions privilégiées de $100 chacune et 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 629 ouest, rue Notre-Dame, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt et unième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Slipper Specialties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Conpanies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-first ' day of May, 1953, incorporating: David Bellam, merchant and manufacturer, of Outremont, Sam Bellam, merchant, Alexander Bellam, foreman, both of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in all kinds of products made of leather, under the name of \"Slipper Specialties Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 preferred shares of $100 each, and 200 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 629 Notre Dame Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1953.L.DESLLETS, 35036-o Deputy Attorney General.- Tar Point Oil Company (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du treizième jour de mai 1953, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat et conseil en Loi de la Reine, Ethel Yussem, secrétaire, fille majeure, de la cité de Montréal, Theodore H.Shapiro, avocat, de Ville Mont-Royal tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais) pétrole, huile et gaz et les exploiter sous le nom de \"Tar Point Oil Company\", (Libre de responsabilité personnelle) avec un capital de $5,000,000, divisé en 5,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce treizième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Tar Point Oil Company (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirteenth day of May 1953,.incorporating: Joseph Shapiro, advocate and Queen's counsel, Ethel Yussem, secretary, spinster, of the city of Montreal, Theodore H.Shapiro, advocate, of the town of Mount Royal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals, petroleum, oil and gas, and deal with the same under the name of \"Tar Point Oil Company\", (No Personal Liability)\", with a capital stock of $5,000,000, divided into 5,000,000 shares of $1 each.The shareholders will incur no personal liability in excess of the amount paid or agreed to be paid to the company for its shares, as provided by section 6 of the said Act.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the AttorneyGeneral this thirteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Tru-Sel Blouse Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du trentième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Hyman M.Schwartz, Moe A.Schwartz et Philip Schwartz, marchands, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements de toutes sortes, sous le nom de \"Tru-Sel Blouse Co.\", avec un capital de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Tru-Sel Blouse Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirthiéth day of April, 1953, incorporating: Hyman M.Schwartz, Moe A.Schwartz, and Philip Schwartz, merchants, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in or with clothing of every sort, under the name of \"Tru-Sel Blouse.Co.\", with a capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each. 2050 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SO juin 1963, Tome 85, N° S5 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce trentième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirtieth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Association Sportive Cclanesc Association Sportive Celanese (Sorel) Inc.(Sorel) Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de Notice is hereby given that underthe provisions la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé of the Quebec Companies' Act, supplementary par le Lieutenant-gouverneur de la province de letters patent, bearing date the twenty-first day Québec, représenté par M.C.Lallichelière, con- of May, 1953, were issued by the Lieutenant-formément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, Governor of the Province of Quebec represented chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, by Mr.C.LaRichelière, in conformity with sec-en date du 21 mai 1953, changeant le nom du tion 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, \"Cercle Celanac Inc.\", constitué en corporation changing the name of the \"Cercle Celanac Inc.\", en vertu de la troisième partie de ladite loi, par incorporated into a corporation under Part III lettres patentes datées du 19 décembre 1950, en of the said Act, by letters patent dated Decem-celui de \"Association Sportive Celanese (Sorel) ber 19, 1950, into that'of \"Association Sportive Inc.\" Celanese (Sorel) Inc.\" Daté du bureau du Procureur général, le 21 Dated at the office of the Attorney General, mai 1953.this twenty-first day of May, 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 35036-o L.DÉSILETS.35036 Deputy Attorney General.Chez Micheline Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires datées du 25 mai 1953.à la compagnie \"Chez Micheline Inc.\", augmentant son capital de $5,000 à $40,000: le capital-actions additionnel étant divisé en .600 actions privilégiées et 100 actions ordinaires de $50 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 25 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Continental Housing Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires datées du 21 mai 1953, à la compagnie \"Continental Housing Corporation\", augmentant son capital-actions par la création de 15,000 nouvelles actions privilégiées de $10 chacune et fixant à la somme de $55,000 le montant avec lequel la compagnie continuera ses opérations.Daté du bureau du Procureur général, le 21 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036 L.DÉSILETS.Chez Micheline Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity wiht section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chagter 276, to the company \"Chez Micheline Inc.\", increasing its capital from $5,000 to $40,000: the additional capital stock being divided into 600 preferred shares and 100 common shares of $5*0 each.Dated at the office of the Attorney General, the 25th day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Continental Housing Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity-with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Continental Housing Corporation\", increasing its capital stock by the creation of 15,000 new preferred shares of $10 each and fixing at the sum of $55,000 the amount with which the company shall continue its operation.s Dated at the office of the-Attorney General, the 21st, day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Dutrempco Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été acosrdé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Dutrempco Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies- Act, supplementary letters patent, bearing date the fifteenth day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 195S, Vol.85, No.25 2051 loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du quinze mai 1953, changeant le nom de la compagnie \"Tremp-Co Ltée \u2014 Ltd\", constituée en coiporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes datées du 3 décembre 1952, en celui de \"Du-trempeo Inc.\" Daté du bureau du Procureur général, le 15 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-p X.DÉSILETS.by Mr.C.LaRichelière, in Conformity with section 2, of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, changing the name of the company \"Tremp-co Ltée \u2014 Ltd\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated December 3, 1952, into that of \"Du-trempco Inc.\" Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Grant-Mills Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 22 mai 1953, à la compagnie \"Grant-Mills Limited\", subdivisant et convertissant 150 actions privilégiées de $100 chacune de son capital autorisé en 3,000 actions communes de $5 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 22 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.La Cie Potvin & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt mai 1953, à la compagnie \"La Cie Potvin & Fils Inc.\", portant son capital de $40,000 à $80,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 20 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Grant-Mills Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-second day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Grant-MPls Limited\", subdividing and converting 150 preferred shares of $100 each of its authorized capital stock into 3,000 common shares of $5 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.La Cie Potvin & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent bearing date the twentieth day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, of the said Act, R.S.Q., 1951, chapter 276, to the company \"La Cie Potvin & Fils Inc.\", carrying its capital stock from $40,000 to $80,000: the additional capital stock being divided into 400 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Lanctot Automobiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovince de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 21 mai 1953, à la compagnie \"Lanctot Automobiles Inc.\", portant son capital de $50,000 à $75,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 21 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Mercantile Trading Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes Lanctot Automobiles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies 'AcC, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter276, bearing date the twenty-first day of May, 1953, to the company \"Lanctot Automobiles Inc.\", carrying its capital stock from $50,000 to $75,000: the additional capital stock being divided into 250 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1953.L.DÉSILETS.35036 Deputy Attorney General.Mercantile Trading Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-second day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with sec- 2052 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SO juin 1958, Tome 86, N° S6 supplémentaires, en date du 22 mai 1953, à la compagnie \"Mercantile Trading Corporation\", augmentant son capital de $20,000 à $40,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 22 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSILETS.Rubylee Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 21 mai 1953, à la compagnie \"Lorintex Sales Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec par lettres patentes datées du 10 avril 1943 sous le nom originaire de \"Lawrence Sales Incorporated\", lequel nom originaire a été changé en celui de \"Lorintex Sales Inc.\" par lettres patentes supplémentaires datées du 27 mars 1945, a) diminuant son capital de $20,000 à $4,000 par l'annulation de 1,600 actions ordinaires de $10 chacune: b) augmentant ledit capital de $4,000 à $60,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 2,600 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune: c) changeant le nom de la compagnie en celui de \"Rubylee Inc.\": b) augmentant le nombre des directeurs de trois (3) à quatre (4).Daté du bureau du Procureur général, le 21 mai 1953.L'Assistant-procureut général, 35036 L.DÉSILETS.Simco Industries Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovince de Québec, représenté par M.C.La-lichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 21 mai 1953, à la compagnie \"Simard & Frères, Cie Ltée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 15 avril 1939, sous le nom originaire de \"Simard et Frère Co.Ltée\", et par lettres patentes supplémentaires en date du 9 mars 1951, changeant inter alia ledit nom originaire en celui de \"Simard & Frères, Cie Ltée\", changeant de nouveau le nom de cette compagnie en celui de \"Simco Industries Inc.\" Daté du bureau du Proéureur général le 21 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉSLLETS.Avis divers AVIS PUBLIC Avis est, par les présentes, donné que \"Ville Emard Baptist Church\", 6572 Boulevard Monk, Montréal, présentera une requête au Lieutenant-gouverneur en Conseil de la province de Québec, tion 2, of the said Act, S.R.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Mercantile Trading Corporation\", increasing its capital stock from $20,000 to $40,000: the additional capital stock being divided into 200 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1953.L.DÉSLLETS, 35036 Deputy Attorney General.Rubylee Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, ni conformity with section 2of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Lorintex Sales Inc.\", incorporated under the said Part I of the Qubeec Companies Act by letters patent dated April 10, 1943, under the original name of \"Lawrence Sales Incorporated\", which original name was changed to that of \"Lorintex Sales Inc.\" by supplementary letters patent dated March 27, 1945, a) reducing its capital from $20,000 to $4,000 by the cancellation of 1600 common shares of $10 each: 6) increasing the said capital from $4,000 to $60,000: the additional capital stock being divided into 2,600 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each: c) changing the name of the company to that of \"Rubylee Inc.\": d) increasing the number of directors from three (3) to four (4).Dated at the office of the Attorney General, the 21st day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036-o Deputy Attorney General.Simco Industries Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-first day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Simard & Frères, Cie Ltée\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent bearing date the fifteenth day of April, 1939, under the original name of \"Simard et Frère Co.Ltée\", and by supplementary letters patent bearing date March 9, 1951, changing inter alia the said original name into that of \"Simard & Frères, Cie Ltée\", changing again the name of this company into that of \"Simco Industries Inc.\" Dated at the office of the Attorney General this twenty-first day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.Miscellaneous Notices PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the \"Ville Emard Baptist Chruch,\" 6572 Monk Boulevard, Montreal, will present a Petition to the Lieut.Gover-nor-in-Council of the Province of Quebec for QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1953, Vol.85, No.25 2053 pour obtenir son incorporation en vertu de la Loi de \"a constitution de certaines ég'ises, chapitre 311, Statuts Refondus 1941 et ses amendements.Montréal, le 25 mai 1953.Les Procureurs de la requérante, CERINI & JAMIESON.231, ouest, rue St-Jacques, 34916-22-4 Montréal.AVIS PUBLIC Avis câl, par.les présentes, donné que \"Emmanuel Baptist Church,\" 350 avenue Woodland, cité de Verdun, présentera une requête au Lieutenant-gouverneur en Conseil de la province de Québec, pour obtenir son incorporation en vertu de la Loi de la constitution de certaines églises, chapitre 311 des Statuts Refondus de la province de Québec, 1941 et ses amendements.Montréal, le 25 mai 1953.Les Procureurs de la requérante, CERINI & JAMIESON, 231 ouest rue St-Jacques, 34915-22-4 Montréal.AVIS PUBLIC Avis est, par les présentes, donné que \"Grace Gospel Chapel\", une des Églises de la \"Christian Brethen\" de la province de Quebec, présentera une requête au Lieutenant-gouverneur en Conseil de la province de Québec, pour obtenir son incorporation, en vertu de la Loi de la constitution de certaines Églises, chapitre 311 des Statuts refondus de la province de Québec, 1941 et amendements.Montréal, 30 mai 1953.Les Procureurs de la requérante, CERINI & JAMIESON.231 ouest, rue St-Jacques, Montréal.34968-23-4 Avis de changement de nom (Loi des syndicats professionnels) .Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a autorisé, le neuf juin 1953, le changement de nom de la \"Fédération Nationale des Employés Municipaux et Scolaires- du Canada Inc.\", dont la formation a été autorisée le 20 mai 1948, sous le nom originaire de \"Fédération Nationale des Employés Municipaux du Canada Inc.\", et dont le siège social est situé à Montréal, en celui de \"Fédération Nationale des Employés des Corporations Municipales et Scolaires du Canada Inc.\", conformément aux dispositions des articles 7 et suivants de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162.Domié au bureau du Secrétaire de la province le dix juin 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la province, 35040-o LUCIEN DARVEAU.Laval University Student Guides Règlement N° 3 Concernant le nombre de membres du bureau de direction Il est proposé par M.André Letarte, secondé par Léonard Larue, et il est résolu à l'unanimité des membres présents que: incorporation under the Church Incorporation Act, Chapter 311 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941 and Amendments.Montreal, May 25th, 1953.CERINI & JAMIESON, Solicitors for Petitioner, 231, St-James St.West, 34916-22-4-0 Montreal.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that \"Emmanuel Baptist Church\", 350 Woodland Avenue, City of Verdun, will present a Petition to the Lieut.Governor-in-Council of the Province of Quebec for incorporation under the Church Incorporation Act, Chapter 311 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941, and Amendments Montreal, May 25th, 1953.CERINI & JAMIESON, Solicitors for Petitioner, 231, St-James St.West, 34915-22-4-o Montreal.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the \"Grace Gospel Chapel\", one of the Christian Brethren Churches in the Province of Quebec, will present a Petition to the Lieut.-Governor-in-Council of the Province of Quebec for incorporation under the Church Incorporation Act, Chapter 311 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941 and Amendments.Montreal, May 30th, 1953.CERINI & JAMIESON, Solicitors for Petitioner.231 St.James St.West, Montréal.34968-23-4-o Notice of change of name (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary, on June ninth 1953, authorized the changing of the name of the \"Federation Nationale des Employés Municipaux et Scolaires du Canada Inc.\", the formation of which has been authorized on May 20, 1948, under the original name of \"Fédération Nationale des Employés Municipaux du Canada Inc.\", and whose head office is located in Montreal, to that of \"Fédération Nationale des Employés des Corporations Municipales et Scolaires du Canada Inc.\" and such, pursuant to the provisions of section 7, and the following of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162.Given at the office of the Provincial Secretary, June tenth 1953.LUCIEN DARVEAU, 35040 Acting Under Secretary of the Province.Laval University Student Guides By-law No.8 Concerning the number of the Board of Directors It is proposed by Mr.André Letarte, seconded by Léonard Larue, and it isjunanimously resolved by members present that: 2054 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 juin 1953, Tome 85, N° 25 \"Le bureau de direction de la corporation constituée sous le nom de \"Laval University Student Guides\" soit dorénavant constitué de cinq (5) membres au lieu de quatre (4) tel que fixé dans les lettres-patentes d'incorporation.\" Québec, ce 17 avril 1953.Le Secrétaire, 35041-o (Signé) GUY METHÉ.\"The Board of Directors of the corporation constituted under the name of \"Laval University Student Guides\", shall hereafter be composed of five (5) members instead of four (4) as stipulated in the Letters Patent of incorporation.\" Quebec, this April 17, 1953.(Signed) GUY METHÉ, 35041 Secretary.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de Deschaillons\", pour l'étude la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le trente mai 1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Deschaillons, dans le comté de Lotbinièrc.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 35042-o LUCIEN D Alt VEAU.NOTICE 1 ' (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C.C.de Deschaillons\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May 30th, 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at Deschaillons, in the county of Lotbinièrc.LUCLEN DARVEAU, 35042 Acting Under Secretary of the Province.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de Mistassini\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le douze juin 1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Mistassini, dans le comté de Roberval.Le Sous-secrétaire de la Province, 35043-o JEAN BRUCHÉSI.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C.C.de Mistassini, for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on June twelfth 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at Mistassini, in the county of Roberval.JEAN BRUCHÉSI, 35043 Under Secretary of the Province.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"C.A.E.Employees Credit Union\", en date du 26 mai 1953, dont le siège social est situé à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province,' le 9 juin 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la province, 35044-o LUCIEN DARVEAU.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"C.A.E.Employees Credit Union\" dated May 26, 1953 whereof the head office is at Montreal, in.the judicial district of Montreal and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, June 9, 1953.LUCLEN DARVEAU, 35044 Acting Under Secretary of the Province.Spino Construction and Equipment Limited Extrait des minutes d'une assemblée spéciale des directeurs de \"Spino Construction and Equipment Limited\" tenue à Montréal, le 8 mai 1953: Règlement A-l Il est décrété par le présent règlement A-l de \"Spino Construction and Equipment Limited\" comme suit: 1° Le nombre des directeurs de la compagnie est augmenté de trois à cinq, et le règlement N° 3 des rèblements généraux de la compagnie est amendé en conséquence.2° Quant au quorum pour les assemblées des directeurs, le deuxième paragraphe du règlement N° 5 des règlements généraux de la compagnie Spino Construction and Equipment Limited Extract from minutes of a special meeting of Directors of \"Spino Construction and Equipment Limited\", held in Montreal, on May 8, 1953: By-Law A-l It is enacted by said By-law A-l of \"Spino Construction and Equipment Limited\", as fol- .ows: 1.The number of Directorso f the Company is increased from three to five, and By-law No.3 of the Company's by-laws is amended according- 2.As to quorum for Directors' meetings, the second paragraphe of By-law No.5 of the general by-laws of the Company is amended by striking QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1963, Vol.86, No.26 2055 est amende en y remplaçant le chiffre \"deux\" par le chiffre \"trois\".(Sceau) Le Président, P.SPINO.Le Secrétaire, 35046-o MARIO SPINO.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Reliance Employees Credit Union\", en dcte du 1er juin 1953, dont le siège social est situé à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 4 juin 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la province, 35045-o LUCIEN DARVEAU.Avis est, par les présentes donné, que sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province, en date du 5 juin 1953, a approuvé les amendements à la section 2 de l'article X et à la section 9 de l'article XIII des règlements de \"The Traffic Club of Montreal Incorporated\" tels qu'adoptés à l'assemblée tenue le 21 mai 1953, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (R.S.Q.1941, chapitre 276).Daté du bureau du Secrétaire de la Province, ce 6e jour de juin 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 35047 LUCIEN DARVEAU.Interknit Limited Règlement N° 24 Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs de la compagnie ci-dessus, de trois à quatre.\"Attendu que par lettres patentes constituant en corporation la compagnie, en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, le nombre des directeurs de la compagnie a été fixé à trois (3) \u2022 Et attendu qu'il a été reconnu nécessaire d'augmenter le nombre des directeurs de la compagnie de trois (3) à quatre (4); En conséquence, la compagnie \"Interknit Limited,\" par ses directeurs, décrète que le nombre des directeurs de la compagnie soit et est, par les présentes changé de trois (3) à quatre (4).\" Le Président, HARRY KIRSCH.Le Secrétaire, 35051 MAY ROTHMAN.Ridgewood Housing: & Development Company Règlement N° S (a) (a) Augmentant le nombre des directeurs de la compagnie de quatre (4) à cinq (5).Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de cinq (5) directeurs.Certifié vraie copie du règlement N° 3 (a) (a) passé à une assemblée du bureau des directeurs tenue le 12e jour de mai 1953, et approuvé par les actionnaires à une assemblée tenue à cette fin le môme jour.Le Secrétaire, 35052 CAMPBELL LEACH.out the numeral \"two\" and replacing it by the numeral \"three\".(Seal) P.SPINO, President.MARIO SPINO, 35046 Secretary.Notice is hereby given that the Honourabla the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Reliance Employees Credit Union\" under date June 1st, 1953 whereof the head office is at Montreal, in the judicial district of Montreal and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, June 4, 1953.LUCIEN DARVEAU, 35045 Acting Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the amendments to Section 2 of Article X and to Section 9 of Article XII of the By-Laws of \"The Traffic Club of Montreal Incorporated\", as adopted at the meeting held on May 21st, 1953, were approved by the Honourable the Provincial Secretary on June 5th, 1953, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act (R.S.Q.1941, chapter 276).Dated at the office of the Provincial Secretary, this 6th day of June, 1953.LUCLEN DARVEAU, 35047-o Acting under Secretary of the Province.Interknit Limited By-laio No.24 A by-law to increase the number of Directors of the above Company from three to four.\"Whereas by Letters Patent incorporating the Company under Part I of the Quebec Companies' Act, the number of Directors of the Company was fixed at three (3) \u2022 And whereas it is considered desirable to increase the number of the Company's Directors from three (3) to four (4)- Now therefore, \"Interknit Limited\", by the Directors thereof enacts that the number of the Company's Directors be and is hereby changed from three (3) to four (4).\" HARRY KIRSCH, President.MAX ROTHMAN, 3505l-o Secretary.Ridgewood Housing & Development Company By-laio No.3 (a) (a) Increasing the directorate of the company from four (4) to five (5) \"The affairs of the Company shall be managed by a Board of five (5) directors.\" Certified true copy of By-law No.3 (a) (a) passed at a meeting of the Board of Directors held on the 12th day of May, 1953, and approved by the Shareholders at a meeting held for that purpose on the same day.CAMPBELL LEACH, 35052-o Secretary. 2056 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SO juin 1963, Tome 86, N\" S6 (P.G.2906-51) Britannia Demolition Limitée Britannia Demolition Limited Extrait du règlement N° 40 des règlements de la compagnie.Règlement N° 40 Un règlement pour modifier certaines dispositions des règlements généraux de la compagnie.Il est par les présentes décrété comme règlement N° 40 de la compagnie comme suit: (0.(2) Le règlement N° 9 des règlements de la compagnie est modifié en augmentant le nombre des directeurs de la compagnie de trois à quatre.Certifie vraie copie.Le Secrétaire, 35055-o ELLE LACOMBE.(P.G.16539-52) Universal Safe & Vault, Inc.Règlement N° 6 Adopté par les directeurs et approuvé par les actionnaires de la compagnie le 24 janvier 1953: \"Le nombre des directeurs de la compagnie sera porté de trois à sept, comprenant un Président, deux vice-présidents, un secrétaire-trésorier, et trois directeurs.\" Certificat Je, soussignée, Claire Pinet, secrétaire de Universal Safe & Vault, Inc., certifie par les présentes que le règlement ci-dessus a été régulièrement adopté par les directeurs de la compagnie, au cours d'une assemblée régulièrement convoquée, à laquelle tous sans exception étaient présents, et tenue le 24ième jour de janvier 1953, à 10 heures a.m., au N° civique 19 de la rue Queen, à Granby, district de Bedford.Je certifie de plus que ce règlement, tel qu'adopté par les directeurs, a été par la suite approuvé le même jour, soit le 24ième jour de janvier 1953, à 11 heures a.m., au cours d'une assemblée générale spéciale de tous les actionnaires, dûment et régulièrement convoquée.A cette assemblée, tous les actionnaires de la compagnie sans exception étaient présents, et ont tous voté en faveur de l'adoption de ce règlement ci-dessus.Certifie vrie copie.(Sceau) 35056-o CLAIRE PINET.Paroisse de Saint-Henri de Taillon Comté du Lac-Saint-Jean Tirage d'obligation Les obligations suivantes, émises en vertu du règlement numéro 129, ont été tirées au sort: Dénomination de $100.00: C-3, C-44, C-50, C-53 Dénomination de $500.00: D-72, D-136 Les dites obligations seront remboursables le premier août 1953, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt.Le Secrétaire-trésorier, 35058-o ANTONIO SIMARD.(A.G.2906-51) Britannia Démolition Limitée Britannia Demolition Limited x \u2014 Excerpt of By-law No.40 of the By-laws of the Company.By-Law N°.40 A By-law to modify certain provisions of the general By-laws of the Company.The following is hereby enacted as By-law No.40 of the Company: (1) \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 (2) By-law No.9 of the company's by-laws is amended by increasing the number of the directors of the company from three to four.Certified true copy.ELLE LACOMBE, 35055 Secretary.(A.G.16539-52) Universal Safe & Vault, Inc.By-Law No.5 Adopted by the Directors and approved by the shareholders of the Company, January 24, 1953: \"The number of directors of the Company shall be increased from three to seven, including a president, two vice-presidents, one secretary-treasurer, and three directors.\" Certificate I, Claire Pinet, the undersigned, secretary of Universal Safe & Vault, Inc., hereby certify that the abovementioned By-law has been duly enacted by the directors of the Company at a meeting duly called, at which all, without exception, were present, and held the 24th day of January 1953, at 10 o'clock a.m., at civic number 10 Queen Street, at Granby, district of Bedford.I moreover certify that said By-law was subsequently approved the same day, that is the 24th day of January 1953, at 11 o'clock a.m., at a special general meeting of all the shareholders,duly called in accordance with regulations.At said meeting, all the shareholders without exception were present, and all voted in favor of the adoption of the aforesaid By-law.Certified true copy.(Seal) 35056 CLAIRE PINET.Parish of Saint Henri de Taillon County of Lake St-John Drawing of Bonds The following bonds, issued under By-law 129, have been drawn by lots: Denomination of $100.00: C-3, C-44, C-50, C-53 Denomination of $500.00: D-72, D-136 The said bonds shall be redeemable on the 1st of August 1953, from which date they shall cease to bear interest.ANTONIO SIMARD, 35058-o Secretary-Treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1953, Vol.86, No.26 2057 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Building Products Employees Credit Union\", en date du 28 mai 1953, dont le siège social est situé à Ville La Salle, dans le district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétariat de la province le 13 juin 1953.Le Sous-secrétaire de la province, 35057-o - JEAN BRUCHSÉI.Collège des Médecins et Chirurgiens de la province de québec AVIS DE SUSPENSION Par décision du Conseil de discipline en date du 4 juin 1953, le docteur Emile Morin domicilié à Saint-Grégoire, comté de Montmorency, a été suspendu de l'exercice de la profession de médecin et chirurgien pour un mois à compter du 16 juin 1953.Le Régistraire du Collège des Médecins et Chirurgiens de la province de Québec, 35065-o (Signé) JEAN PAQUIN, M.D.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Coopérative Téléphonique de Lemieux\", en date du 4 juin 1953, dont le siège social est situé à Lemieux, dans le comté de Nicolet, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 13 juin 1953.Le Sous-secrétaire de la Province, 35066-o JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Building Products \"Employees Credit Union\" under date the 28th day of May, 1953 whereof the head office is at Ville La Salle, in the judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of June, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35057 Under Secretary of the Province.College of Physicians and Surgeons of the Province of Quebec NOTICE OF SUSPENSION Following a decision taken by the Council on Discipline, dated June 4th, 1953, Doctor Emile Morin, residing at Saint-Grégoire, county of Montmorency, has been suspended from the practice of medicine and surgery for one month, as from June 16th, 1953.(Signed) JEAN PAQUIN, M.D., Registrar of the College of Physicians and Surgeons 35065 of the Province of Quebec.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Coopérative Téléphonique de Lemieux\", under date the fourth day of June, 1953, whereof the head office is at Lemieux, in the county of Nicolet, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this thirteenth day of June, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35066 Under Secretary of the Province.Chartes \u2014 Abandon de Alloy Foundry Inc.Conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec, la compagnie \"Alloy Foundry Inc.\", donne, par les présentes, avis qu'elle s'adressera au Procureur général de_ la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte et son annulation à compter d'une date qu'il lui plaira de fixer.Daté à Merrickville, Ont., ce lOième jour de juin 1953.Alloy Foundry Incorporated, Le Secrétaire, 35048 ARTHUR W.HÉROUX.El Sol Mines, Limited AVIS Conformément aux dispositions de la loi des compagnies de Québec, \"El Sol Mines, Limited,\" donne par les présentes avis public qu'elle demandera la permission d'abandonner sa charte et de faire fixer une date à compter de laquelle la compagnie sera dissoute.Montréal, le 16 juin 1953.Le Secrétaire, 35062-o F.J.DOLAN.Charters \u2014 Surrender of Alloy Foundry Inc.Under the provisions of the Quebec Companies' Act, \"Alloy Foundry Inc.,\" hereby gives notice that this Company will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its Charter and its cancellation from a date to be fixed by them.Dated at Merrickville, Ont., this 10th day of June, 1953.Alloy Foundry Incorporated, ARTHUR W.HÉROUX, 35048-o Secretary.\u2022 El Sol Mines, Limites NOTICE Under the provisions of the Quebec Companies' Act \"El Sol Mines, Limited'' hereby gives Notice that it will make application for the acceptance of surrender of its Charter and to fix a date upon and from which the Company shall be dissolved.Montréal, 16th June 1953.F.J.DOLAN, 35062-o Secretary. 2058 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 juin 1958, Tome 85, N° 25 Compagnie autorisée à faire des affaires Avis est donné que la compagnie \"Columbia Cellulose Company, Limited\" a été dûment autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec.Les pouvoirs conférés à ladite compagnie par sa charte seront limités à ceux accordés aux corporations de môme nature créées en vertu des Lois de la province de Québec, et la compagnie sera sujette aux même formalités telles que prescrites par les Lois existantes de cette Province.Le bureau principal de la compagnie dans la province de Québec est au N° 1242 rue Peel, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal dans la Province, aux fins de recevoir les assignations dans toute poursuite ou procédure prise contre elle, est M.Louis A.Lapointe, c.r., de ladite cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 12ièmc jour de juin 1953.Le Sous-secrétaire de la Province, 35036 JEAN BRUCHÉSI.Company Licensed to do Business Notice is hereby given that the company \"Columbia Cellulose Company, Limited\", has been duly licensed to carry on business in the Province of Quebec.The powers conferred upon the said Company by its charter shall be limited to those granted to coqwrations of like nature created in virtue of the laws of the Province of Quebec, and the Company shall be subject to the same formalities as are prescribed by the exsiting laws of this Province.The principal office of the Company in the Province of Quebec is at No.1242 Peel Street, in the city and Judicial District of Montreal.Its chief agent in the Province for the purpose of receiving service in any suit or proceeding taken against it, is Mr.Louis A.Lapointe, Q.C., of the said city of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of June, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35036-o Under-Secretary of the Province.Compagnies dissoutes Avis est donné que la compagnie \"Reed Realties, Limited\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec par lettres patentes datées du 6 mars 1914, et ayant son siège social en les cité et district judiciaire de Montréal, a été dissoute à compter du lOième jour de juin 1953, conformément aux dispositions de la Loi de la liquidation volontaire des compagnies à fonds social (R.S.Q.1941, chapitre 278).Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 12 juin 1953.Le Sous-secrétaire de la Province, 35054 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.15726-52) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Girouard Limousines de Luxe Inc.\",constituéé en corporation par lettres patentes en date du 5 juin 1935.Avis est de plus donné qu'à compter du qinzne juin 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le 16 juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35036-o L.DÉISLETS.(P.G 17894-52) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilit S décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Orange Security Company\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 10 octobre 1928.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze juin 1953, ladite compagnie a été dissoute.Companies Dissolved Notice is hereby givent that \"Reed Realties, Limited\", a company incorporated under the Quebec Companies Act, by letters patent dated March 6th., 1914, and having its head office in the city and judicial district of Montreal, has been dissolved on and from the 10th day of June, 1953, pursuant to the provisions of the Winding-up Act (R.S.Q.1941, chapter 278).Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of June, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35054-o Under-Secretary of the Province.(A.G.15726-52) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27^of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Girouard Limousines de Luxe Inc.\", incorporated by Letters Patent, dated the fifth day of June 1935.Notice is also hereby given that from and after the fifteenth day of June 1953, the said company* shall be dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this June sixteenth 1953.L.DÉSILETS, 35036 Deputy Attorney General.(A.G.17894-52) \u2022Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attor-nay General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Orange Security Company\", incorporated by Letters Patent, dated the tenth day of October 1938.Notice is also hereby given that from and after the fifteenth day of June 1953, the said company shall be dissolved. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1958, Vol.85, No.25 2059 Daté du bureau du Procureur général, le 16 Dated at the office of the Attorney General, juin 1953.this sixteenth day of June 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSLLETS, 35036-o L.DÉSILETS.35036 Deputy Attorney General.Département des Affaires municipale Department of Municipal Affairs Le soussigné donne avis que, tel que demandé par une résolution du 1er juin 1953 du conseil municipal de Wenceslas, comté de Nicolet, et conformément aux dispositions de l'article 130 du Code municipal, il a été décrété, en date du 15 juin 1953, que les publications de tous les avis publics, règlements, résolutions ou ordres de la dite corporation, sauf celles requises dans la Gazette officielle de Québec, se feront, à l'avenir dans la langue française seulement.Le présent avis est publié en conformité de l'article 131 du Code municipal.(10 George VI, chapitre 55, section 2).Québec, le 15 juin 1953.Le Sous-ministre des Affaires municipales, 35037-o JEAN-LOUIS DOUCET, C.R., Annexion a la ville de Port Alfred A qui les présentes peuvent concerner: Avis est par les présentes donné que, par l'arrêté en conseil N° 681, du 11 juin 1953, et conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi des cités et villes, (S.R.Q.1941, chapitre 233), il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver le règlement N° 192 du conseil de la ville' de Port-Alfred, et de décréter que, à compter de la date de la publication du présent avis, le territoire mentionné au dit règlement et décrit di-dessous, soit tout le territoire de\" la municipalité du village de Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie.Ce territoire est le suivant: Le territoire de la municipalité du village de Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie telle qu'érigée par la proclamation du 20 mai 1908 moins la partie incluse dans la municipalité du village de Port-Alfred érigée par la proclamation du 22 avril 1918, est compris dans les limites suivantes: partant d'un point sur la rive sud de la Baie-des Ha! Ha! situé à 12 arpents à l'est du pont de Barachois: de là, une ligne allant vers le sud-est dans la direction des lignes latérales de lot du rang 1-Sud du canton de Bagot, jusqu'à un point situé à 10 arpents de la dite rive: de là, une ligne parallèle à la rive de la dite baie et à 10 arpents de la dite rive allant d'abord vers l'ouest jusque vers.le milieu du lot N° 75 du cadastre, officiel de la paroisse de Saint-Alexis, dans le canton Bagot: puis vers le nord jusqu'à la \\\\-> mite sud de la ville de Port-Alfred \u2014 laquelle s'établit par la ligne sud des lots du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Alexis, 94-171, 94-170, 94-14, 94-B, le prolongement de cette dernière ligne à travers le lot 479-71 (chemin public), la ligne sud des lots.Nos.94-C, 94-F et le prolongement de cette dernière ligne jusqu'à la laisse des basses eaux de la Baie-des-Ha! Hâ! la dite limite sud de la ville de Port-Alfred jusqu'à la rive de la Baie-des-Ha! Ha! et enfin cette dite rive en la suivant sensiblement vers le sud-est et l'est jusqu'au point de départ.Québec, le 11 juin 1953.Le Sous-ministre des Affaires municipales.35037-o JEAN-LOUIS DOUCET, C.R., The undersigned gives notice, that, as requested by a resolution of June 1st, 1953, of the Municipal Council of Wenceslas, county of Nicolet and pursuant to the provisions of Article 130 of the Municipal Code, it has been enacted under date of June 15, 1953, that the publication of all public notices, by-laws, resolutions or orders of the said corporation, with the exception of those required in the Quebec Official Gazette, be made, thereafter in the French language only.The present notice is published in conformity with Article 131 of the Municipal Code (10 George VI, chapter 55, section 2).Quebec, June 15, 1953.JEAN-LOUIS DOUCET, Q.C., 35037 Deputy Minister of Municipal Affaris.Annextion to the town of Potr Alfred To whom it may concern: Notice is hereby given that, by Order in Council No.681, dated June 11, 1953, and pursuant to the provisions of Section 43 of the Cities and Towns Act (R.S.Q.1941, Chapter 233), the Lieutenant-Governor has been pleased to approve By-Law No.192 of the Council of the Town of Port-Alfred, and to enact that, as from the date of publication of this notice, the territory mentioned in said By-law and described herein-under, that is, all the territory of the municipality of the village of Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie.This territory is the following: The territory of the municipality of the village of Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie as erected by proclamation dated May 20, 1908 minus the part included in the municipality of the village of Port-Alfred erected by proclamation dated April 22, 1918 is comprised in the following limits: commencing at a point on the south bank of Baie-Ha! Ha! situated at 12 arpents east of the Barachois bridge: thence, a line running south-easterly in the direction of the lot lateral lines of Range I-South of the township of Bagot, extending to a point situated at 10 arpents from the said bank: thence, a line parallel to the bank of the said bay and at 10 arpent from the said bank, running firstly towards the west extending as far as the middle of lot No.75 of the official cadastre of the parish of Saint-Alexis, in the township of Bagot: thence northerly as far as the south limit of the town of Port-Alfred, that which is established by the south line of the lots of the officialc adastre of the parish of Saint-Alexis, 94-171, 94-170, 94-14, 94-B, the extension of the said line running across lot 479-71 (public road), the south line of lots Nos.94-C, 94-F and the extension of this said line as far as the low-watermark of Baie-des-Ha! Ha!, the said south limit of the town of Port-Alfred extending to the banks of Baie-des-Ha! Ha: and lastly following this said bank slightly to the south east and esaterly as far as the starting point.Quebec, June 11, 1953.JEAN-LOUIS DOUCET, Q.C., 35037 Deputy Minister of Municipal Affairi. 2060 GAZETTE OFFICIELLE J)E QUÉBEC, Québec, 20 juin 1953, Tome 85, N° 25 Département de l'Instruction publique N° 597-53.Québec, le 4 juin 1953.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Bristol, dans le comté de Pontiac, et d'annexer, pour les contribuables protestants seulement, à la municipalité scolaire protestante d'Onslow, même comté, le territoire décrit ci-dessous, savoir: Les lots suivants du canton de Bristol, dans les rangs V, VI et VII (5, 6 et 7), situés à l'est du N6 13 (le lot N° 13 exclu moins aussi les parties des lots 14, 15 et 16, situés au nord de la tivière Quyon) : dans le rang VLTI (8), cette partie du lot 17-a, située au sud de la rivière Quyon: dans le rang IV (4), les lots 14-b, 15-c,16-b,17-b, 17-c et 18 à 26 inclusivement: dans le rang III (3), les lots 25 à 27 inclusivement.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35005-24-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 1452-51 Québec, le 9 juin 1953.Demande est faite que le nom de la municipalité scolaire du village de Rouyn, dans le comté de Rouyn-Noranda, soit changé en celui de \"La municipalité scolaire catholique de Rouyn\".Le Surintendant de l'Instruction publique, 35024-24-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 496-53.Quebec, le 10 juin 1953.R a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 4 juin 1953, d'annexer à la municipalité scolaire de la Ville de Forestville, dans la comté de Saguenay, tout le territoire de la municipalité scolaire du Canton Laval, dans le même comté.Cet arrêté ministériel prendre effet le premier juillet 1953.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35038-o O.J.DESAULNIERS.852-45 Québec, le 11 juin 1953.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 29 mai 1953, de modifier l'item 2 de l'arrêté ministériel N° 71, en date du 22 janvier 1948, concernant l'érection d'une municipalité scolaire distincte sous le nom de Sts-Martyrs-Canadiens, dans le comté d'Abitibi-Est, afin que ladite municipalité scolaire comprenne, à l'avenir, les mêmes limites que celles de la paroisse canonique portant ce nom; le territoire de cette municipalité de Ste-Martyrs-Canadiens, comté d'Abitibi-Est, est décrit comme suit, savoir: \"Dans le canton Béarn, du lot 45 au lac Obals-ki, du rang I (1): du lot 45 au lot 62 inclusivement, des rangs U, UJ et rV (2, 3 et 4): de la rivière Davy au lot 62 inclusivement, des rangs V et VI (5 et 6): de la rivière Davy au lot 62 inclusivement et le lot A, du rang VH (7) : de la rivière Harricana au lot 62 inclusivement dans le rang VDJ (8): les lots 37, 38, 39 et la partie sud de la rivière Clément des lots 41, 42, 43, 44 et 45, et les lots 46 à 62 inclusivement du rang IX (9): Dans le canton Castagnier, du lot 1 au lac Obalski, des rangs II à IV (2 à 4) inclusivement: du lot 1 au lot 31 inclusivement des rangs, V à IX (5 à 9) inclusivement.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35038-o O.J.DESAULND3RS.Department of Education No.597-53.Quebec, June 4th, 1953.Application is made to detach from the school municipality of Bristol, in the county of Pontiac, and to annex, for the Protestant taxpayers only, to the Protestant School Municipality of Onslow, same county, the territory described herein-under, to wit: The following lots of Bristol Township, in ranges V, VI and VII (5, 6 and 7), situate east of No.13 (Lot No.13 excluded, less also parts of lots 14, 15 and 16, situate north of the Quyon River): in range VIII (8), that part of lot 17-a, situate south of the Quyon River: in range IV (4), lots 14-b, 15-c, 16-b, 17-b, 17-c and 18 to 26 inclusively: in range III (3) lots 25 to 27 inclusively.0.J.DESAULNIERS,.35005-24-o Superintendent of Education.No.1452-51 Quebec, June 9, 1953.Application is made that the name of the School Municipality of the Village of Rouyn, in the county of Rouyn-Noranda, be changed into that of \"The Catholic School Municipalit of Rouyn\".O.J.DESAULNIERS, 35024-24-2 Superintendent of Education.No.496-53 Quebec, June 10, 1953.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council has, by Order in Council, dated June 4, 1953, been pleased to annex to the school municipality of the town of Forestville, in the county of Saguenay, all the territory of the school municipality of the Township of Laval, in the same county.This Order in Council will come into effect the first day of July 1953.O.J.DESAULNIERS, 35038 Superintendent of Education.No.852-45 Quebec, June 11, 1953.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated May 29,1953, to amend item 2 of Order in Council No.71, dated January 22, 1948, concerning the erection of a separate school municipality under the name of Sts.Martyrs-Canadiens, in the county of Abitibi East, in order that henceforth the said school municipality will include the same limits as those of the canonical parish bearing the same name: the territory of said municipality of Sts.Martyrs-Canadiens, county of Abitibi-East, is described as follows, to wit: \"In Township Beam, from lot 45 to Lake Obalski, Range I (1): from lot 45 to lot 62 inclusive, Ranges n, ni and IV (2, 3 and 4): from Davy River to lot 62 inclusive, Ranges V and VI (5 and 6): from Davy River to lot 62 inclusive and lot A, Range VH (7): from Harri-cana River to lot 62 inclusive, Range Vlll (): lots 37, 38, 39 and the southern part of Clément River, lots 41, 42, 43, 44 and 45, and lots 46 to 62 inclusive of Range IX (9): In the township of Castagnier, from lot 1 to Lake Obalski, Ranges n to IV (2 to 4) inclusive: from lot 1 to lot 31 inclusive, Ranges V to IX (5 to 9) inclusive.O.J.DESAULNIERS.35038 Superintendent of Education. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1953, Vol.85, No.25 2061 N° 828-52 Quebec, le 10 juin 1953.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 4 juin 1953, de détacher de la paroisse de Ste-Victoire, dans le comté d'Arthabaska, les lots du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Victoire, comprenant les numéros 56 à 61 inclusivement, pour les annexer à la municipalité scolaire de la Ville de Victoriaville, dans le même comté.Cet arrêté ministériel prendre effet le premier juillet 1953.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35038-o O.J.DESAULNIERS.N° 378-53.Québec, le 12 juin 1953.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Grenville N° 3, dans le comté d'Argentcuil, en celui de \"'.?ointe-aux-Chênes\", même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35059-25-2-o O.J.DESAULNIERS.No.828-52 Quebec, June 10, 1953.His Honour the Lieutcnant-Governor-in-Coun-cil has been pleased by Order in Council dated June 4th, 1953, to detach from the parish of Ste.Victoire, in the County of Arthabaska, lots number 56 to 61 inclusive, of the official cadastre of the parish of Ste.Victoire, in order to annex them to the school municipality of the town of Victoriaville, same county.This Order in Council will take effect the first day of July 1953.0.J.DESAULNIERS, 35038 Superintendent of Education.No.378-53 Quebec, Jjune 12, 1953.Application is made to change the name of the school municipality of Greenville No.3, in the county of Argenteuil, into that of \"Pointe-aux-C'hênes\", same county.Ô.J.DESAULNIERS, 35059-25-2 Superintendent of Education.département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel du Canton d'Otis division d'enregistrement de Chicoutimi.Avis est par la présente donné que les lots 24 et 25 sont ajoutés au Rang VI, les lots 23 du Rang VI, 24 et 25 du Rang VII sont corrigés, en vertu de l'article 2174A du Code civil.Quebec, le 3 juin 1953.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 35039-o AVILA BÊDARD.Department of Lands and Forests NOTICE Official Cadastre of the Township of Otis registration division of Chicoutimi.Notice is hereby given that lots 24 and 25 are added at Range VI, lots 23 of Range VI and 24 and 25 of Range VII are corected in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, June the 3rd, 1953.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÊDARD, 35039-o Deputy Minister.Département du Travail CORRECTION L'avis de modification publié dans la Gazette officielle de Québec du 13 juin 1953, relatif aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans la région des Trois-Rivières, est dorrigé comme suit: La municipalité de St-Adclphe, comté de Champlain, et un rayon de cinq (5) milles de ses limites doit faire partie de la zone IV.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 18 juin 1953 35078-o ERRATUM Dans la Gazette officielle de Québec, édition du 25 avril 1953, volume 85, numéro 17, à la page 1468, les mots \"à l'article VH\" apparaissant à l'amendement 10° de l'arrêté en conseil numéro 448-A du 16 avril 1953, concernant des modifications au décret relatif aux métiers de la métallurgie dans la région de Québec, doivent se lire \"à l'article Vin\".35078-o Department of Labour CORRECTION The notice of amendment published in the Quebec Official Gazette on June 13, 1953, relating to the barber and hairdressing trades in the region of Trois-Rivières, is corrected as follows: The municipality of St.Adelphe, county of Champlain, and a radius of five (5) miles from its limits is included in zone IV.GÉRARD TREMBLAY, Deputy-Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 18, 1953.35078-o ERRATUM In the Quebec Official Gazette, issue of April 25, 1953, vol.85, No.17, page 1468, the words \"to section VTI\" mentioned in the 10th amendment of Order in Council No.448-A of April 16, 1953, concerning amendments of the decree relating to the metal trades in the district of Quebec, shall read \"to section VIII\".35078-o 2002 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 Juin 1053, Tome Sô, A'0 25 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans la cité de Hull et la ville de Buckingham, rendue obligatoire par le décret numéro 2246 du 27 août 1941.lui ont présenté une requête à I effet d'amender ledit décret, dans sa teneur modifié, de la façon suivante: 1° Les prix minima apparaissant à l'article Y pour les services ci-après mentionnés seront remplacés par les suivants: \"Coupe de cheveux: Pour les adultes des deux sexes: Les lundi, mardi, mercredi et jeudi.SO.65 Les vendredi, samedi et veille de Noël et du Premier de l'An.0.75 Pour les enfants de moins de 14 ans: Les lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.50 Les vendredi, samedi et veille de fêtes chômées.0.65 Barbe.0.50\" 2° Les trois premiers alinéas du paragraphe \"6\" de l'article III seront remplacés par les suivants: \"b) Pour les barbiers et les coiffeurs, les heures de travail sont réparties de la façon suivante: Zone I: Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi: de S.00 a.m.à 6.30 p.m.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazelle officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 20 juin 1953.35078-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux établissements commerciaux de la ville de Roberval, rendue obligatoire par le décret numéro 109 du 3 février 1949, lui ont présenté une requête à l'effet d'amender ledit décret, dans sa teneur modifiée, de la façon suivante: 1° Le paragraphe \"a\" de l'article I sera remplacé par le suivant: \"a) Les mots \"magasin de détail\" désignent tout établissement où se fait en détail l'un des commerces suivants: nouveauté', marchandise sèche, épicerie, boucherie, épicerie-boucherie, épicerie-licenciée, quincaillerie, ferronnerie, chaussure, chapeau, fourrure, tabac, cigares, cigarettes, fleurs, objets de fantaisie, bibelots, chocolats et bonbons, biscuits et gâteaux, matériaux de construction, peinture, papier tenture, articles de plomberie, meubles, articles de sports, radios, laveuses-électri.|iies, poêles et accessoires électriques, farine et moulée, instruments de musique, machines à coudre, désignent aussi les bazars de 80.05 à 81.00 ou plus, les magasins généraux, les librairies et les papeteries, les salles NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the barber and hairdressing trades in the city of Hull and the town of Buckingham, rendered obligatory by the decree number 2246 of August 27, 1941, have submitted to him a request to amend the said decree, as amended, as follows: 1.The minimum prices mentioned in section Y for the services hereafter mentioned are replaced by the following: \"Haircut: Male and female adults: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.80.65 Friday.Saturday and Christmas and New Year's eves.0.75 Children under 14 years of age: Monday, Tuesday.Wednesday and Thursday.0.50 Friday, Saturday and holiday eves.0.65 Shave.0.50\" 2.The first three paragraphs of subsection \"6\" of section III will be replaced by the following: \"/*) For barbers and hairdressers, hours of work shall be distributed as follows: Zone I: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday: 8.00 a.m.to 6.30 p.m.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazelle, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties mav wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 20, 1953.35078-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette.Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the commercial establishments of the town of Roberval, rendered obligatory by the decree number 109 of February 3, 1949, have submitted to him a request to amend the said decree, as amended, as follows: 1.Subsection \"a\" of section I will be replaced by the following: \"a) The words \"retail store\" mean any establishment engaged in the following trades, on a retail basis: Novelties, dry goods, grocery, butcher shop, grocery-butcher shop, licensed grocery, hardware, shoes, hats, furs, tobacco, cigars, cigarettes, flowers, fancy goods, bibelots, chocolate and bonbons, biscuits and cakes, building materials, paint, wall-paper, plumbing articles, furniture, sporting goods, radios, electric washers, stoves, ranges and electric accessories, flour and feed mashes, musical instruments, sewing machines, including bazars (80.05 to $1.00 or more), general stores, libraries and stationeries, sale rooms (on sample or catalogue).The following, however, is not included: cafes. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 20th, 1958, Vol.85, No.25 2063 de vente sur échantillon ou sur catalogue.Il y a toutefois exception pour les restaurants, cafés, pharmacies, débits d'essence et hôtels.\" 2° Le paragraphe \"c\" suivant sera ajouté à l'article V: \"c) Tout travail exécuté les dimanches et les jours de fêtes chômées doit être rémunéré au taux de temps double par rapport au salaire régulier.\" 3° Le deuxième alinéa de l'article VI sera remplacé par les suivants: Doivent aussi être chômés et payés les fêtes civiques, le Vendredi-Saint jusqu'après l'office et le jour de la fête du Sacré-Cœur jusqu'après l'office également.Il n'y, a pas de travail les dimanches.Quand un des jours chômés énumérés ci-dessus tombe durant la semaine de vacances payées d'im salarié, ce dernier a droit à une journée additionnelle.Cette journée lui sera donnée au choix de l'employeur.Toute réclamation pour rajustement de salaires ne doit jamais couvrir une période dépassant six (6) mois.\" 4° Le paragraphe \"a\" de l'article VII sera remplacé par le suivant: \"a) Après une année de services pour le même employeur, tout salarié a droit à une (I) semaine de vacances payées par année.Après deux (2) années de services ou plus, pour le même employeur, tout salarié a droit à une (1) semaine de vacances payées plus une (1) journée additionnelle pour chaque année de services jusqu'à concurrence de deux (2) semaines de vacances payées.\" 5° Les paragraphes \"d\" et \"c\" de l'article VII seront remplacés par les suivants: \"
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.