Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 31 décembre 1954, vendredi 31 (no 53)
[" Tome 86, N° 53 3921 Vol.86, No.53 Drapeau de la province de Québec adopte par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE OF QUEBEC Québec, vendredi 31 décembre 1954 Quebec, Friday, December 31st, 1954 AVIS AUX INTÉRESSÉS NOTICE TO INTERESTED PARTIES Règlements Rules 1° Adresser toute correspondance à: lTmpri- 1.Address all communications to: The Queen's meur de la Reine, Québec.Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues 2.Transmit advertising copy in the two official officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When same is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at the frais des intéressés, d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official rates.3° Spécifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates dant, exception est faite lorsque ces annonces hereinbelow set forth.Exception being made doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé when the said advertising copy is to be published doit alors acquitter la facture sur réception et several times.The interested party shall then avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière pay upon reception of his account and before insertion est suspendue, sans autre avis et sans the second insertion: otherwise this last insertion préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine will be suspended without further notice and qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute without prejudice as regards the rights of the somme versée en plus.Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, la vente de document?, etc., 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are sont strictement payables d'avance.strictly payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank mandat de banque ou mandat-poste.or postal money order.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Quebec Official Gazette is published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter.6270 3922 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 1954, Tome 86, N° 53 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, a cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion : 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 26G lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avi's ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1910.31753 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lincsto the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: S7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"b\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governcment House.Quebec, June 27th, 1940.31753 \u2014 1-52 Lettres patentes (P.G.12986-54) Arcs & Frères Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier décembre 1954, constituant en corporation: Clovis Ares, industriel, d'Outremont, Roger Ares, industriel, de Pointe-aux-Tremblcs, et Jacques Raymond, comptable agréé, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux, constructeurs et menuisiers, sous le nom de \"Ares & Frères Ltée\", avec un capital divisé en 1,000 actions sans valeur au pair ou nominale et en 600 actions privilégiées de S25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Pointeaux-Trembles, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.' L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.Letters Patent (A.G.12986-54)^ Arcs & Frères Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December, 1954, incorporating: Clovis Ares, industrialist, of Outremont, Roger Ares, industrialist, of Pointe-aux-Trembles, and Jacques Raymond, chartered accountant, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors, builders and joiners, under the name of \"Ares & Frères Ltée\", with a capital stock of 1,000 shares of nominal or no par value and into 600 preferred shares of 825 each.The head office of the company will be at Pointe-aux-Trembles, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954 C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1954, Vol 86, No.53 3923 (P.G.12939-54) Autobus Dorchester Bus, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a « été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six novembre 1954, constituant en corporation: Ls-Philippe Chouinard, comptable, d'Armagh, Jules Paré, avocat, de Montmagny, tous deux du district judiciaire de Montmagny, et Maurice Nolin, industriel, des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires généralement comme voituriers publics, sous le nom de \"Autobus Dorchester Bus, Inc.\", avec un capital total de 880,000, divisé en 800 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(P.G.12880-54).Bouchard & Gravel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf novembre 1954, constituant en corporation: J.-Adélard Bouchard, industriel, Marius Gravel; entrepreneur, et Alida Boily, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Marius Gravel, tous de Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Bouchard & Gravel Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 150, rue St-Jean, Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(P.G.13096-54) Canadian Passengers Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze décembre 1954, constituant en corporation sans capital-actions: Jean Filion, avocat, de Ville Mont-Royal, Paul Gérin-Lajoie, avocat, d'Outremont, et André Ducharme, avocat, de Pont-Viau, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir et défendre les intérêts des usa-ders des transports en commun par chemin de fer dans la Province de Québec, sous le nom de \"Canadian Passengers Association\".Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 810,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(A.G.12939-54) Autobus Dorchester Bus, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of November, 1954, incorporating: Ls-Philippe Chouinard, accountant, of Armagh, Jules Paré, advocate, of Montmagny, both of the judicial district of Montmagny, and Maurice Nolin, industrialist, of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To generally carry on business as public carriers, under the name of \"Autobus Dorchester Bus, Inc.\", with a total capital stock of 880,000, divided into S00 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General.(A.G.12880-54) Bouchard & Gravel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of November, 1954, incorporating: J.-Adélard Bouchard, industrialist, Marius Gravel, contractor, and Alida Boily, housewife, wife contractually separate as to property of the said Marius Gravel, all of Jonquière, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on the operations of general and building contractors, under the name of \"Bouchard & Gravel Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at 150 St-Jolm Street, Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General.(A.G.13096-54) Canadian Passengers Association Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of December 1954, to incorporate as a corporation without share capital: Jean Filion, advocate, of the town of Mount Royal, Paul Gérin-Lajoie, advocate, of Outremont, and André Ducharme, advocate, of Pont-Viau, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To further and protect the interests of railroad passengers in the Province of Quebec, under the name of \"Canadian Passengers Association\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 810,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of December 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General. 3924 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SI décembre 195A, Tome 86, N° 63 (P.G.12813-54) Club Social des Musiciens de Québec Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois novembre 1954, constituant en corporation sans capital-actions: Gerald L.Bou-dreau, Jean Dumas, Florian Bernatchez, Roland Desjardins, Denys Walsh, Marcel Lefrançois, musiciens, Roger Angers, chef d'orchestre, Mar-lène Angers, musicienne, fille majeure, tous de Québec, Paul-Emile Robitaille, musicien, de Saint-Romuald, et Charles Pouliot, musicien, de Beauport, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Grouper les musiciens de Québec faisant partie de l'Association des Musiciens de Québec, local 119, filiale de l'American Federation of Musiciens of United States of America in Canada et toutes autres personnes intéressées dans l'art musical, pour fins de récréations et d'activités sportives, artistiques, athlétiques et sociales, sous le nom de \"Club Social des Musiciens de Québec Inc.\".Le montant auquel spnt limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $100,000.Le siège social de la corporation sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(P.G.129G2-54) Compagnie Sutton et Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier décembre 1954, constituant en corporation: Jacques de Billy, avocat, de Lévis, Gilles de Billy, avocat, de Sillery, et Elizabeth A.Pennington, secrétaire, célibataire, de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchand général et de négociant de poisson, sous le nom de \"Compagnie Sutton et Fils Ltée\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Grande-Rivière, district judiciaire de-Gaspé.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(P.G.12927-54) Conserves Ste-Anne Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six novembre 1954, constituant en corporation: Rolland Simard, boucher-épicier, Armand Soucy, contremaître, tous deux de Sainte-Anne-des-Plaines, district judiciaire de Terre-bonne, et Emile Déom, policier, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : La mise en conserves des fruits, légumes, viandes, denrées de toutes sortes, sous le nom de \"Conserves Ste-Anne Ltée\", avec un capital (A.G.12813-54) Club Social des Musiciens de Québec Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of November, 1954, to incorporate as a corporation without share capital; Gerald L.Boudrcau, Jean Dumas, Florian Bernatchez, Roland Desjardins, Denys Walsh, Marcel Lefrançois, musicians, Roger Angers\", orchestra leader, Marlène Angers, musician, fille majeure, all of Quebec, Paul-Emile Robitaille, musician, of Saint-Romuald, and Charles Pouliot, musician, of Beauport, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To group together the musicians of Quebec who form part of the Association of Quebec Musicians, Local 119, a branch of the American Federation of Musicians of United States of America in Canada, and any other persons interested in music, for recreational, sporting, artistic, athletic and social activities, under the name of \"Club Social des Musiciens de Québec Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the coqwration may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General.(A.G.12962-54) ^ Compagnie Sutton et Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the'Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December 1954, incorporating: Jacques de Billy, advocate, of Levis, Gilles de Billy, advocate, of Sillery, and Elizabeth A.Pennington, secretary, spinster, of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of general fish merchant and trader, under the name of \"Compagnie Sutton et Fils Ltée\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Grande-Rivière, judicial district of Gaspé.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General.(A.G.12927-54) Conserves Ste-Anne Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of November, 1954, incorporating: Rolland Simard, butcher-grocer, Armand Soucy, foreman, both of Sainte-Anne^des-Plaines, judicial district of Terrebonne, and Emile Déom, policeman, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To preserve fruits, vegetables, meats, foodstuffs of all kinds, under the name of \"Conserves Ste-Anne Ltée\", with a total capital stock of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 81st, 195A, Vol.86, No.53 3925 total de $50,000, divisé en 4,000 actions communes de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Anne-des-Plaines, district judiciaire de Terre-bonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre 1954.L'Assistai!f-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(P.G.12841-54) Cossetlc & Frères Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier décembre 1954, constituant en corporation: Louis-Georges Cossette, Paul-André Cossette, Charles-Henri Cossette, commerçants, Arthur Gagnon, comptable, et Jean Beaulieu, avocat, tous d'Amos, district judiciaire d'Abiti-bi, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Cossette & Frères Ltée\", avec un capital total de $60,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Amos, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.L'Assistant-procu reu r général, 38901-o C.E.CANTIN.850,000, divided into 4,000 common shares of 810 each and into 2,000 preferred shares of 85 each.The head office of the company will be at Sainte-Anne-des-Plaines, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General.' (A.G.12841-54) Cossette & Frères Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters paten t have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December, 1954, incorporating: Louis-Georges Cossette, Paul-André Cossette, Charles-Henri Cossette, dealers, Arthur Gagnon, accountant, and Jean Beaulieu, advocate, all of Amos, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Cossette & Frères Ltée\", with a total capital stock of 860,000, divided into 4,000 common shares of 810 each and into 2,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company will be at Amos, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General.(P.G.12886-54) Crelinsten Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf novembre 1954, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat et conseil en loi de la Reine, de Westmount, Ethel Yussem, secrétaire, fille majeure, et Jean McFarlane, dactylo, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Gérer, administrer et surveiller les placements de la compagnie; faire le commerce de toutes catégories de fruits, légumes et aliments, sous le nom de \"Crelinsten Inc.\", avec un capital divisé en 5,000 actions sans valeur nominale ou au pair et 5,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901 C.E.CANTIN.(P.G.12901-54) C & M Textiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six novembre 1954, constituant en corporation: Jean-Paul Verschclden, Maurice D.Godbout et Roland Bourret, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires dans toutes spécialités du commerce de manufacturiers et marchands (A.G.12886-54) Crelinsten Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of November, 1954, incorporating Joseph Shapiro, advocate and Queen's Counsel, of Westmount, Ethel Yussem, secretary, spinster of the full age of majority, and Jean McFarlane, typist, spinster of the full age of majority, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manage, administer and supervise the company's investments; to trade in all classes of fruit, vegetables and food stuffs, under the name of \"Crelinsten Inc.\", with a capital stock divided into 5,000 shares having no nominal or par value and into 5,000 preferred shares of $100 each.\u2022 The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 3890l-o Deputy Attorney General.(A.G.12901-54) C & M Textiles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of November, 1954, incorporating: Jean-Paul Verschclden, Maurice D.Godbout and Roland Bourret, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of any branches of the business of manufacturers of and dealers in 3926 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 1954, Tome 30, N° 68 d'articles tricotés et textiles et produits et sous-produits des textiles, sous le nom de \"C & M Textiles Inc.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 50 actions ordinaires de S100 chacune, 1,000 actions privilégiées catégorie \"A\" de S10 chacune et 2,500 actions privilégiées catégorie \"B\" de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 7506 rue St-Hubcrt, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901 C.E.CANTIN.(P.G.13027-54) Durochcr Automobiles Ltd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept décembre 1951, constituant en corporation: Claude Durochcr, vendeur, Isabelle Lc-may, sténographe, fille majeure, tous deux de Montréal, et Kose-Aimée Poudrette, sténographe, fille majeure, de Bouchervillc, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de véhicules automobiles et exploiter des garages, stations de gazoline, sous le nom de \"Durochcr Automobiles Ltd\", avec un capital total de 8120,000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 1,000 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lachinc, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(P.G.12896-54) Greenstone Textiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf novembre 1954, constituant en corporation: William Greenstone, marchand, Sydney Phillips, avocat et Rose-Marie Bour-going, secrétaire, célibataire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de produits textiles, marchandises en pièces et tissus, sous le nom de \"Greenstone Textiles Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901 C.E.CANTIN.(P.G.12872-54) Guarantee Handbags Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du premier décembre 1954, constituant en cor- knitwear and textiles and textile products and by-products, under the name of \"C & M Textiles Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 50 common shares of 8100 each and into 1,000 class \"A\" preferred shares of 810 each and 2,500 class \"B\" preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 7506 St.Hubert St., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38901-o Deputy Attorney General.(A.G.13027-51) Durochcr Automobiles Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of December, 1954, incorporating: Claude Durochcr, salesman, Isabelle Ix;may, stenographer, spinster, both of Montreal, and Rose-Ai-méc Poudrette, stenographer, spinster, of Bouchervillc, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in automotive vehicles and to operate garages, gazoline stations, under the name of \"Durocher Automobiles Ltd\", with a total capital stock of 8120,000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 1,000 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Lachine, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of December, 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General.(A.G.12896-54) Greenstone Textiles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of November, 1954, incorporating: William Greenstone, merchant, Sydney Phillips, advocate, and Rose-Marie Bourgoing, secretary, unmarried, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in textiles, piece-goods and fabrics under the name of \"Greenstone Textiles Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 500 common shares having a par value of S10 each and into 350 preferred shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38901-o Deputy Attorney General.(A.G.12872-54) Guarantee Handbags Co.Notice is h rcby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December, 1954, incorporating: Samuel Chait, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 195A, Vol.36, No.51 3927 poration: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch et Abraham Sinister, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de sacoches, bourses et nouveautés, sous le nom de \"Guarantee Handbags Co.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901 C.E.CANTIN.(P.G.12898-54) Kciisom Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes eu date du trente novembre 1954, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, et Abraham Shuster, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Agir comme une corporation de portefeuille et de placement, sous le nom de \"Kensom Inc.\", avec un capital total de §40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901 C.E.CANTIN.(P.G.12819-54) L'Association des Marchands d'Automobiles du Nord-Ouest du Québec .Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier décembre 1954, constituant en corporation sans capital-actions: Réal Caouette, Maurice Bergeron, tous deux de Iiouyn, et J.Horace Thibault, de Noranda, tous vendeurs d'automobiles, dans le district judiciaire de Rouyn-Noranda, pour les objets suivants: Promouvoir et sauvegarder les intérêts professionnels et commerciaux de ses membres et agir à titre consultatif ou comme mandataire dans tous les domaines concernant ces intérêts, sous le nom de \"L'Association des Marchands d'Automobiles du Nord-Ouest du Québec\".Le montant auquel sont limités 'les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Rouyn, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(P.G.12713-54) Lindsay, Clcndinncng Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date Harry L.Aronovitch and Abraham Shuster, ail advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in handbags, purses, novelties, under the name of \"Guarantee Handbags Co.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and into 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954.C.E.CANTIN, 3S901-o Deputy Attorney General.(A.G.12898-54) Kensom Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of November, 1954, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, and Abraham Sinister, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as a holding and investment corporation, under the name of \"Kensom Inc.'\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38901-o Deputy Attorney General.(A.G.12819-54) _ \u2022 L'Association des Marchands d'Automobiles du Nord-Ouest du Québec Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first dav of December, 1954, to incorporate as a corporation without share capital: Réal Caouette, Maurice Bergeron, both of Rouyn, and J.-Horace Thibault, of Noranda, all automobile salesmen, in the judicial district of Rouyn-Noranda, for the following purposes: To further and safeguard the professional and commercial interests of its members and act as consultant or representative in all fields conccncd therewith, under the name of \"L'Association des Marchands d'Automobiles du Nord-Ouest du Québec\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Rouyn, judicial district \"of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954.C.E.CANTIN, 3S901 Deputy Attorney General.(A.G.12713-54) Lindsay, Clcndiimeng Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day 3928 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 1951, Tome 86, N° 53 du premier décembre 1954, constituant en corporation: Albert Malouf, avocat, Lily Malouf, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, et Peter Shorteno, avocat, de Ville St-Laurent, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme courtiers de douanes, entreposeurs, expéditeurs, roidiers et voi-turiers, sous le nom de \"Lindsay, Clendinncng Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de S109 chacune et 200 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4S6 rue St-Jean, chambre 37, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901 C.E.CANTIN.(P.G.12389-54) Linton Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf novembre 1954, constituant en corporation: Paul N.Lord, entrepreneur, Eléo-nor Lord, ménagère, épouse séparée de biens dudit Paul N.Lord, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, et André Gingras, courtier en assurances, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Linton Construction Co.Ltd.\", avec un capital total de 85,000, divisé en 500 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(P.G.12760-54) Métropole Towing Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier décembre 1954, constituant en corporation sans capital-actions: Olivier Cornett, agent, William Cornett, garagiste, et Emile Moroni, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Servir de médium d'échange de connaissances, d'idées et d'expériences en matière d'automobiles, de trafic et apporter à ses membres des moyens d'organisation, d'information, d'avis et d'assistance en tout ce qui concerne l'automobile et le tourisme, sous le nom de \"Métropole Towing Association\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $5,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.of December, 1954, incorporating: Albert Malouf, advocate, Lily Malouf, secretary, spinster of the full age of majority, both of Montreal, and Peter Shorteno, advocate, of Ville St.Laurent, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of custom house brokers, warehousemen, forwarders, carriers and carters, under the name of \"Lindsay, Clendin-neng Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 486 St.John Street, Room 37, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 38901-o Deputy Attorney General.(A.G.12389-54) Linton Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of November, 1954, incorporating: Paul N.Lord, contractor, Éléonor Lord, housewife, wife separate as to property of the said Paul N.Lord, and duly authorized by the latter for those present purposes, and André Gingras, insurance broker, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate as a building company, under the name of \"Linton Construction Co.Ltd.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 50 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General.(A.G.12760-54) Métropole Towing Association Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December 1954, to incorporate as a corporation without share capital: Olivier Cornett, agent, William Cornett, garage-keeper, and Emile Moroni, accountant, all of the city and judicial district of Montreal,- for the following purposes: To act as a medium in exchanging knowledge, ideas and experiences concerning automobiles and traffic, and impart to its members means of organization, information, advice and assistance in all that which concerns automobile and touring, under the name of \"Métropole Towing Association\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited is $5,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954 .C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 195A, Vol.86, No.53 3929 (P.G.12955-54) Paul Bélanger Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier décembre 1954, constituant en corporation: Jules Bélanger, gérant, Raymond Bélanger, médecin, Bland inc Gagnon Bélanger, veiive, et Simone Bélanger Bordclcau, épouse séparée de biens de Marc-Yvon Bordclcau, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous de La Sarre, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'articles de ménage, meubles, instruments de musique, jouets, appareils- électriques, radios, appareils de télévision, phonographes, instruments et machines à enregistrer, à coudre, outillage de chauffage, réfrigérateurs, équipement et machines agricoles, industriels et commerciaux, sous le nom de \"Paul Bélanger Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à La Sarre, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o ^ C.E.CANTIN.(P.G.12949-54) Pleasant View Hotel Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du premier décembre 1954, constituant en corporation: Armand Rousseau, Wesley Hyndman Bradley et Douglas S.Howard, tous avocats et conseils en loi de la Reine, de la cité de Sherbrooke, district judiciaire de St-François, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme hôteliers et restaurateurs, sous le nom de \"Pleasant View Hotel Limited\", avec un capital divisé en 800 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune et 2,000 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera au village de Hatley-Nord, district judiciaire de St-François.\u2022 Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901 C.E.CANTIN.(P.G.12918-54) / State Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf novembre 1954, constituant en corporation: Max S.Kaufman, avocat, de West-mount, Joseph Roy Hoffman, avocat, et Oscar Respitz, étudiant, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles, de propriétés réelles et immobilières, sous le nom de \"State Realties Inc.\", avec un capital total de S40.000, divisé en 40 actions ordinaires de 8100 chacune et 360 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.(A.G.12955-54) Paul Bélanger Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December 1954, incorporating: Jules Bélanger, manager, Raymond Bélanger, physician, Blandine Gagnon Bélanger, widow, and Simone Bélanger Bordclcau, wife separate as to property of Marc-Yvon Bordclcau, and duly authorized by the latter for the purposes herein, all of La.Sarre, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To deal in household articles, furniture, musical instruments, toys, electrical apparatus, those of radio and television, phonographs, recording instruments and machines, sewing machines, heating equipment, refrigerators, agricultural, industrial and commercial equipment and machinery, under the name of \"Paul Bélanger Inc.\", with a total capital of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at La Sarre, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954.C.E.CANTIN, -38901 Deputy Attorney General.(A.G.12949-54) Pleasant View Hotel Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December, 1954, incorporating: Armand Rousseau, Wesley Hyndman Bradley and Douglas S.Howard, all advocates and Queen's Counsel, of the city of Sherbrooke, judicial district of St.Francis, for the following purposes: To carry on the business of hotel and restaurant keepers, the name of \"Pleasant View Hotel Limited\", with a capital stock divided into 800 preferred shares of a par value of S100 each and into 2,000 shares without nominal or par value.The head office of the company will be at the village of North Hatley, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954.C.E.CANTIN, 3S901-o Deputy Attorney General.(A.G.12918-54) State Realties Inc.Notice is hereby given that, under 'Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the \u2022Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of November, 1954, incorporating: Max S.Kaufman, advocate, of Westmount, Joseph Roy Hoffman, advocate, and Oscar Respitz, student, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, real property and immoveables, under the name of \"State Realties Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 40 common shares of $100 each and into 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 3930 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 1951, Tome 86, N° 53 Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901 C.E.CANTIN.(P.G.13018-54) Trotlicr & Cie Ltée \\, Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur delà province de Québec des lettres patentes, en date du sept décembre 1954, constituant en corporation: Evaristc Trottier, manufacturier, Jacques Trottier, marchand, et Raymond Massi-cotte, assistant-gérant, tous de Saint-Casimir, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Agir comme épicier en général, sous le nom de \"Trottier & Cie Ltée,\", avec un capital total de 899,000, divisé en 490 actions communes de 8100 chacune et en 500 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Casimir, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le sept décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 3890l-o C.E.CANTIN.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38901-o Deputy Attorney General.(A.G.13018-54) Trotlicr & Cie Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent'have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of December, 1954, incorporating: Évariste Trottier, manufacturer, Jacques Trottier, merchant, and Raymond Massicottc, assistant-manager, all of Saint Casimir, judicial district of Quebec, for the following purposes: To act as a grocer generally, under the name of \"Trottier & Cie Ltée\", with a total capital stock of 899,000, divided into 490 common shares of 8100 each and 500 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Saint Casimir, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of December, 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires (P.G.12724-54) Anglo-Scandinavian Investment Corporation of Canada Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, supplémentaires, en date du vingt décembre 1954, à la compagnie \"Anglo-Norwcgian Holdings Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 22 mars 1929, 1° réduisant son capital: le capital-actions annulé étant divisé en 20,000 actions privilégiées de S100 chacune et en 55,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair; 2° convertissant les 445,000 actions ordinaires restantes sans valeur au pair ou nominale en 445,000 actions ordinaires de 82.80 chacune; 3° augmentant son capital de 81,246,000 à 85,600,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 1,555,000 actions ordinaires de 82.80 chacune; 4° changeant son nom en celui de \"Anglo-Scandinavian Investment Corporation of Canada\"; 5° augmentant le nombre des directeurs de sept (7) à onze (11).Daté du bureau du Procureur général, le vingt décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(P.G.12830-54) Greenwood Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-neuf novembre 1954, à la compagnie \"The Fair Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par Supplementary Letters Patent (A.G.12724-54) A nglo-Scandinavian Investment Corporation of Canada Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December twentieth, 1954, to the company \"Anglo-Norwegian Holdings Limited\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated March,22nd, 1929, 1.reducing its capital stock: cancelled capital stock being divided into 20,000 preferred shares of 8100 each and into 55,000 common shares without nominal or par value; 2.converting the remaining 445,000 common shares without nominal or par value into 445,000 common shares of 82.80 each; 3.increasing its capital stock by 81,246,000 to 85,600,000: the additional capital stock being divided into 1,555,000 common shares of 82.80 each; 4.changing its name into that of \"Anglo-Scandinavian Investment Corporation of Canada\"; 5.increasing the number of Directors from seven (7) to eleven (11).Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General.(A.G.12830-54) Greenwood Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated twenty-ninth day of November, 1954, to the company \"The Fair Inc.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated January 25, 1929, a) QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1951, Vol 86, No.53 3931 lettres patentes en date du 25 janvier 1929, a) changeant son nom en celui de \"Greenwood Enterprises Inc.\" ; b) étendant ses pouvoirs.* Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(P.G.12941-54) Hygrade Food* Products Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la .première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dé Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-cinq novembre 1954, à la compagnie \"Hygrade Packers Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 10 août 1932, sous le nom originaire de \"Hygrade Food Products Incorporated\", et par lettres patentes supplémentaires en date, respectivement, du 16 mars 1951 et du 3 septembre 1954, ces dernières changeant ledit nom originaire en celui de \"Hygrade Packers Limited\", changeant de nouveau son nom en celui de \"Hygrade Food Products Incorporated\".Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(P.G.12942-54) Les Soeurs de l'Enfant Jésus du Puy Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé.par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-six novembre 1954, accordant des pouvoirs additionnels à la corporation \"Les Sœurs de l'Enfant Jésus du Puy\", à savoir: le pouvoir de posséder les biens immobiliers jusqu'à concurrence de deux millions de dollars (82,000,000.).Daté du bureau du Procureur général, ie vingt-six novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(P.G.12250-54) Monterey Shoe Stores Inc.Avis est donné qu'en Vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-neuf novembre 1954, à la compagnie \"Monterey Shoe Market Inc.\", constituée en corporation en vertu de la dite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 9 septembre 1954, a) changeant son nom en celui de \"Monterey Shoe Stores Inc.\"; b) augmentant le nombre de ses directeurs de trois (3) à quatre (4).Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38901-o C.E.CANTIN.(P.G.13026-54) Quebec Land Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a plu au Lieutenant-gouverneur de la province de Québec de corriger les lettres patentes sup- changing its name into that of \"Greenwood Enterprises Inc.\"; b) extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General.(A.G.12941-54 Hygrade Food Products Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-fifth day of November 1954, to the company \"Hygrade Packers Limited\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated August 10, 1932, under the original name of \"Hygrade Food Products Incorporated\", and by supplementary letters patent dated, respectively, March 16th, 1951, and September 3rd, 1954, the latter changing the said original name to that of \"Hygrade Packers Limited\", changing once again its name to \"Hygrade Food Products Incorporated\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38901 \u2022 Deputy Attorney General.(A.G.12942-54) Les Sœurs de l'Enfant Jésus du Puy Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-sixth day of November 1954, granting additional powers to the corporation \"Les Sœurs de l'Enfant Jésus du Puy\", to wit: the power to liold immoveable property not exceeding two million dollars (82,000,000.).Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 3S901 Deputy Attorney General.(A.G.12250-54) Monterey Shoe Stores Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated November twenty-ninth 1954, to the company \"Monterey Shoe Market Inc.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated September 9, 1954, a) changing its name into that of \"Monterey Shoe Stores Inc.\"; b) increasing the number of its directors from three (3) to four (4).Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General.(A.G.13026-54) Quebec Land Company Notice is hereby given* that under Part I of the Quebec Companies' Act, His Honour the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec has been pleased to correct supplementary 3932 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SI décembre 1954, Tome 86, N° 58 plémentaires du 29 juin 1912 et celles du 25 juin 1947, de la compagnie \"Quebec Land Company\", de la manière suivante: en suppriment le mot \"The\" du nom de la compagnie, de façon que ce nom se lise: \"Quebec Land Company\", au lieu de The Quebec Land Company.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 19541 L'Assistant-procureur général, 3890l-o C.E.CANTIN.letters patent dated June 29, 1912 and June 25th, 1947, of the \"Quebec Land Company\" in the following manner: striking out the word \"The\" from the Company's name, in order that it may read: \"Quebec Land Company\", in lieu of The Quebec Land Company.Dated at the office of the Attorney General, the sixteenth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 38901 Deputy Attorney General.Actions en séparation de biens Province de Québec, District d'Arlhabaska, Cour Supérieure, N° 10-024.Dame Blanche Labrie, épouse commune en biens de Louis Bossé, ouvrier de Thctford Mines, demanderesse; vs Ledit Louis Bossé, défendeur.Une action en séparation de biens a été intentée en cette cause, le 7 décembre 1954.Plessisville, le 14 décembre 1954.Le Procureur de la demanderesse, 38911-0 EDOUARD HOUDE.Dame Alphéda Béliveau, épouse de Gabriel Boisvert de Stratford a formé contre son mari une demande de séparation de biens.Le Procureur de la demanderesse, 38915-0 J.-ARMAND DROUIN.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1253 Québec, le 17 décembre 1954.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Parc National des Laurentides.Attendu que le développement du Parc National des Laurentides, comme l'ampleur des opérations forestières et la construction du Boulevard Talbot dans ce parc, ont créé des problèmes de circulation et de surveillance qui ne sont pas, prévus dans les règlements du Parc; Attendu que certains règlements établis par l'arrêté en conseil numéro 1131, du 29 avril 1931, ne conviennent plus aux conditions existantes et qu'il y a lieu de les amender.Vu l'article 9, du chapitre 156, des statuts refondus 1941; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable ministre de la chasse: Que certains règlements établis par l'arrêté en conseil numéro 1131, du 29 avril 1931, soient annulés, remplacés et amendés comme suit: Que le paragraphe 4 de l'article 1 soit annulé et remplacé par le suivant: Il est défendu à toute personne porteur d'un permis de promenade ou d'un permis de traverser le parc sur l'une des routes nationales, de circuler sur d'autres routes ou de s'arrêter ailleurs qu'aux endroit de repos le long de la route, ou aux hôtelleries du parc, soit le Gîte, le Relais ou l'Étape; Actions for separation as to property Province of Quebec, District of Arthabaska, Superior Court, N.10-024.Dame Blanche Labrie, wife common as to property of Louis Bossé, workman of Thctford Mines, plaintiff; vs The said Louis Bossé, defendant.An action in separation as to property has been instituted in this case on December 7th, 1954.Plessisville, December 14th, 1954.EDOUARD HOUDE, 3891 l-o Attorney for the plaintiff.Dame Alphéda Béliveau, wife of Gabriel Boisvert, of Stratford, has instituted an action in separation as to property against her husband.J.-ARMAND DROUIN, 38915 Attorney for the plaintiff.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1253 Quebec, December 17 th, 1954.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the Laurentides National Park.Whereas developments in the Laurentides National Park and the expansion of the forestry operations as well as the construction of the Talbot Boulevard in this park, have created unforeseen traffic and superintendence problems, not provided for in the Park by-laws; Whereas certain by-laws established by, Order in Council number 1131, of April 29th, 1931, are no longer suitable to existing conditions and that it is expedient to amend the same.In view of article 9, of chapter 156, of the Revised Statutes of 1941; Therefore, it is ordained, upon the proposition of the Honourable the Minister of Game and Fisheries: That certain by-laws established by Order in Council 1131, of April 29th, 1931, be cancelled, replaced and amended as follows: That paragraph 4 of article 1 be cancelled and replaced by the following: It is forbiddent for any person, carrying a travel permit or a permit to cross the park upon one of its national highways, to circulate upon other highways or to stop elsewhere than in rest places along the highway, or at hotels in the park, to wit: the \"Gîte\", the \"Relais\" or the \"Étape\"; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1951, Vol 86, No.53 3933 Que le paragraphe suivant soit ajouté a l'article 1 des règlements: Il est défendu à toute personne travaillant dans le parc, de circuler sur d'autres routes que celles conduisant à son lieu de travail; Que l'article 3 soit annulé et remplacé par le suivant: Les garde-chasse et les gardiens préposés au parc peuvent confisquer, au bénéfice de la Couronne, toute arme à feu, piège, trappe, collet ou autre engin de chasse possédés en contravention avec la loi ou les règlements du parc; Que l'article 4 soit annulé et remplacé par le suivant: Il est interdit à toute personne, même à un gardien ou à un employé d'un club dont le territoire fait partie du Parc National des Laurentides, d'avoir en sa possession, sans un peJmis spécial, une arme à feu, dans les limites du Parc National des Laurentides; Que les mots contenus dans l'article 5: \"La pêche à l'appât et à la trolle est défendu\" soient remplacé par les mots: l'usage de tout appât ou d'autre leurre est défendu.\" Que l'article 8 soit annulé et remplac par le suivant: Toute personne trouvée en état d'ébriété ou causant du désordre dans les bâtisses uu sur le territoire du Parc Natistcra des Laurentides, ou qui insultera ou molestera les employés du gouvernement dans les exercices de leur fonction, ou qui enfreindra l'un quelconque des règlements, sera arrêtée ou renvoyée du Parc National des Laurentides saeu; préjudic à tout autre recours légal s'il y a lin: Que l'article 9 soit amendée en y joutant, après les mots: \"dommages causés\" les mots: \"et l'amende\"; Que l'article 17 soit annulé et remplacé par par le suivant: Toute personne qui moleste, sur les routes, chemins du parc et ailleurs, ou blesse, avec une automobile, motocyclette, ou autre véhicule moteur, du gibier ou des animaux à fourrure, est passible d'amende tout comme si elle avait chassé ce gibier ou ces animaux à fourrure; Que les mots suivants de l'article 19 soient annulés: \"L'usage du cigare et de la cigarette est interdit dans le parc.\" Que l'article 20 soit annulé et remplacé par le suivant: Pendant les périodes d'alerte, aucun feu pour la cuisson des aliments ne peut être allumé excepté dans des poêles.En d'autres temps, aucun feu à ciel ouvert ne peut être allumé sans être accompagné ou en présence d'un guide ou d'un garde-feu à l'emploi du gouvernement; Que, dans l'article 22, le chiffre 35 est remplacé par le chiffre 50; Que, dans l'article 26, les mots \"du premier mai au 1er novembre de chaque année\", soient remplacés par les mots: \"durant la saison de protection\".L.DESILETS.38902-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1253 Québec, le 17 décembre 1954.Présent.' Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.That the following paragraph be added to article 1 of the by-laws: It is prohibited for any person working in the Park to travel along any other roads than those leading to his work; That article 3 be cancelled and replaced by the following: The game-wardens and the guardians appointed foi* the Park may confiscate, for the benefit of the Crown, any firearms, steel trap, dead-fall, snare or other hunting gear possessed by infringement of the Law or the by-laws of the Park; That article 4 be cancelled and replaced by the following: It is prohibited for any person, even a guardian or employee of a club whose territory forms part of the Laurentides National Park, to have in his possession, without a special permit, a firearm, within the limits of the Laurentides National Park; That the words contained in article 5: \"Bait-fishing and trolling arc forbidden\" be replaced by the words: \"The use of all bait or other lure is prohibited\".That article 8 be cancelled or replaced by the following: Any person found in a state of inebriety or causing disorder in the buildings or upon the territory of the Laurentides National Park, or who shall insult or molest the Government employees in the exercise of their functions or who shall violate any one whatsoever of the by-laws, shall be arrested or expelled from the Laurentides National Park without prejudice to any other legal course, should there be any; That article 9 be amended by adding thereto, after the words: \"damages caused\" the words: \"and fine\"; That article 17 be cancelled and replaced by the following: Any person who mclests, on the highways, Park roads and elsewhere, or who wounds, with an automobile, motorcycle, or other motor vehicle, gome or fur-bearing animals, is subject to be fined in the same was as if he had hunted this game or fur-bearing animals; That the following words of article 19 be cancelled: \"The use of cigars and cigarettes is prohibited in the Park.\" That article 20 be cancelled and replaced by the following: In periods of alert, no fire for the cooking of food may be lighted except in stoves.At other times, outdoor^fires may not be lighted unless one is accompanied by or in the presence of a guide or a fire-warden in the employ of the Government; That, in article 22, the number 35 be replaced, by number 50; That, in article 26, the words: \"from May first to November 1st of each year\", be replaced by the words: \"during the protective season\".L.DESILETS, 38902 Clerk of the executive Council.ORDER IN COUNCIL CHAMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL Number 1253 Quebec, December 17th, 1954.Present: The Lieutenant-Governor in Council. 3934 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SI décembre 195A, Tome 86, N° 53 Extrait Concernant une addition à la Réserve à castor à Manouan.Attendu que, par l'arrêté en conseil numéro 1031, en date du 14 septembre 1949, la partie nord du comté de Laviolette était déclarée région de terrains de chasse enregistrés pour fins de chasse aux animaux à fourrure; Attendu que la presque totalité des trappeurs dans cette région sont des Indiens et que le système de réserve à castor est plus approprié à leurs coutumes de vie.Vu l'article 05, du chapitre 153, «les statuts refondus de Québec, 1941, Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition de l'honorable ministre de la chasse; Que le territoire compris dans la partie du comté de Laviolette, au nord de la ligne extérieure nord-ouest des cantons de Sincenncs, Prémont, Chouinard, Rhéaume et Ingall, soit annexée à la Réserve à castor de Manouan, sujet .aux lois et aux règlements de ladite réserve; Que la partie de l'arrêté en conseil numéro 674; en date du 28 juin 1951, concernant la Réserve à Castor de Manouan, soit modifiée en conséquence; Que l'arrêté en conseil numéro 1031, en date du 14 septembre 1949, soit abrogé.Le Greffier du Conseil Exécutif, 38902-o L.DÉSILETS.Excerpt Concerning an extension to the Beaver Reserve at Manouan.Whereas in accordance with Order in Council number 1031, dated September 14th, 1949, the northern part of the county of Lavillette was declared a region of lands registered for the purpose of hunting fur-bearing animals; Whereas almost all trappers in said region arc Indians and that the Beaver reserve system is more appropriate to their way of living.In view of section 65, chapter 153, of the Revised Statutes of Quebec, 1941, Consequently it is ordained, that upon the recommendation of the Honourable the Minister of Game and Fisheries: That the territory included in that part of the county of Laviolette, north of the northwest outer line of the townships of Sincennes, Prémont, Chouinard, Rhéaume and Ingall, be annexed to the Manouan Beaver Reserve, and subject to the laws and regulations of said Reserve; That, that part of Order in Council number 674, dated June 28th, 1951, concerning the Manouan Beaver Reserve, be modified accordingly; That Order in Council number 1031, dated September 14th, 1949, be repealed.L.DÉSILETS, 38902 Clerk of the Executive Council.Avis divers Avis concernant l'aménagement de forces hydrauliques sur la rivière bazin à 8 milles du village de parent, comté de Laviolette.Conformément au régime des eaux courantes, la corporation du village de Parent comté de Laviolette, après avoir obtenu, par ordre en conseil du gouvernement de la province de Québec daté du 21 août 1954, lequel ordre autorise le ministre des Ressources Hydrauliques à louer à la corporation municipale dudit village, les forces hydrauliques de la rivière Bazin cantons Landry et Bazin, entre le pont du 8 milles du chemin qui conduit de Parent à Clova, et la rivière Pitchpine, demande au Lieutenant-gouverneur en conseil la permission de construire, de maintenir et d'exploiter un barrage en béton et une usine génératrice d'électricité à environ 200 pieds en amont du site dudit pont.Les originaux des plans et devis ont été déposés au Département des Ressources Hydrauliques de la province de Québec, et copies des dits plans et devis ont été déposées au bureau de la division d'enregistrement du comté d'Abitibi à Amos.La demande contenue dans cette requête sera prise en considération le ou après les jours suivants la date de la dernière publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Québec, le 18 novembre 1954.Les Ingénieurs-Conseil, ZACHÉE & PIERRE L ANGLAIS.\u2022 38779-50-4-o Miscellaneous Notices Notice concerning the development of hydraulic power of -the bazin rlver, at 8 miles distance from the village of Parent, county of Laviolette.In accordance with the Water Course Act, the Village Corporation of Parent, county of Laviolette, after having obtained by Order in Council of the Government of the Province of Quebec, dated August 21st, 1954, which Order authorizes the Minister of Hydraulic Resources to lease to the Municipal Corporation of the said village, the hydraulic power resources of the Bazin River, Townships of Landry and Bazin, between the bridge situate at 8 miles from the road leading from Parent to Clova, and the Pitchpine River, prays the Lieutenant-Governor in Council for permission to build, maintain and develop a concrete dam and electric generating station at some 200 feet above the site of said bridge The original plans and specifications have been deposited with the Department of Hydraulic Resources of the Province of Quebec, and copy of said plans and specifications has been deposited at the Registry Office of the Registration Division of the county of Abitibi at Amos.The application contained in this petition will be taken into consideration on or about the days following the date of the last publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Quebec, November 18th, 1954.ZACHÉE -& PIERRE LANGLAIS, Consulting Engineers.38779-50-4 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 195A, Vol.86, No.53 3935 AVIS PUBLIC Avis est, par les présentes, donné que \"Hope Baptist Church\", de Hopetown, Québec, présentera une requête au Lieutenant-gouverneur en Conseil de la province de Québec pour obtenir sa constitution en corporation en vertu de la Loi de la constitution de certaines Églises, chapitre 311 des Statuts refondus de la province de Québec, 1941, et amendements.Montréal, 4 décembre 1954.Les Procureurs de la requérante, CERINI & JAMIESON.231 ouest, rue St-Jacques, Montréal, Que.38778-50-5 The Royal Trust Company Avis est, par les présentes, donné que, par un vote de la majorité des actionnaires à une assemblée générale spéciale dûment convoquée à cette fin et tenue le lGe jour de décembre 1954, le capital-actions de la compagnie The Royal Trust Company a été augmenté de deux millions de dollars (82,000,000) à deux millions cinq cent mille dollars (82,500,000) par la création de ciuq mille (5,000) actions additionnelles d'une valeur au pair de cent dollars (8100) chacune.Montréal, 16 décembre 1954.The Royal Trust Company Le Secrétaire, 38882-52-3 W.E.BICKLEY.Loi du régime des eaux courantes, Statuts refondus, 1941, chapitre 98.Formule 1 1.\u2014 (Article 8) Avis de la demande des plans et devis Avis est donné au public, conformément à l'article 8 de la Loi du régime des eaux courantes, que la Coopérative d'Électricité de Bonavcnture, société coopérative formée sous l'empire de la Loi pour favoriser 1'Electrification rurale, 9 Georges VI chapitre 48, 1945, ayant son siège social à Bonaventure, dans le comté de Bona-venture, se propose de demander l'autorisation de faire faire la construction d'un exhaussement au barrage sur le cours d'eau, dénommé Rivière Hall, qui traverse les lots suivants : 1.\u2014 Lot N° 8 du rang X ouest de Paspébiac.2.\u2014 Lots Nos 4-5-6-7-8 du rang XI ouest de Paspébiac.3 \u2014 Lots Nos 1-2-3-4 du rang XII ouest de Paspébiac.Avis est de plus donné qu'une requête à cette fin, accompagnée des plans et devis indiquant l'emplacement choisi pour la construction de ces ouvrages et les terrains qui seront affectés par le refoulement des eaux, a été transmise au ministre des ressources hydrauliques, et qu'un duplicata de ces plans et devis a été déposé au bureau de la 1ère division d'enregistrement de Bonaventure à New Carlisle.La demande contenue dans la requête sera prise en considération le ou après le jour suivant la date de la dernière publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.La Coopérative d'Électricité de Bonaventure, Requérante.Par le Président, ~ OSCAR BUJOLD.Le Secrétaire-gérant, 38883-52-4-0 SÉBASTIEN FORTIN.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the \"Hope Baptist Church\", of Hopetown, Quebec, will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Quebec for incorporation under the Church Incorporation Act, chapter 311 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941, and amendments.Montreal, December 4th, 1954.CERINI & JAMIESON, Solicitors for petitioner.231 St.James Street West, Montreal, Que.38778-50-5-o The Royal Trust Company, Notice is hereby given that by a vote of the majority of the shareholders at a special general meeting duly called for the purpose and held on the 16th day of December, 1954, the capital stock of The Royal Trust Company was increased from two million dollars (82,000,000) to two million five hundred thousand dollars (82,500,000) by the creation of five thousand (5,000) additional shares of the par value of one hundred dollars (8100) each.Montreal, 16th December, 1954.The Royal Trust Company W.E.BICKLEY, 38882-52-3-o Secretary.Water-Course Act, Revised Statutes, 1941, chapter 98.Form 1 1 \u2014 (Section 8) Application and Notice of Deposit of Plan * and Specifications.Public notice is hereby given in accordance with section 8 of the Water-Course Act, that the Bonaventure Electricity Cooperative, cooperative formed under the act to promote Rural Electrification, 9 Georges VI, chapter 48, 1945, having its head office in Bonaventure in the county of Bonaventure, intends to apply for authorization to have constructed a raise on the dam on the water course which passes across the following lots: 1.\u2014 Lot 8 rang X west of Paspébiac.2.\u2014 Lots 4-5-6-7-8 range XI west of Paspébiac.3.\u2014Lots 1-2-3-4 range XII west of Paspébiac.Notice is also given that a petition to that effect, accompanied by a plan and specifications of such work, showing the site chosen for the construction thereof and the lands which will be affected by the backing up of the water, has been forwarded to the Minister of Hydraulic Resources, and that à\" duplicate of such plan and specifications has been deposited at the registry office, of the first registration division of Bonaventure at New Carlisle.The application contained in the petition will be taken into consideration on or after the day following the' date of the last publication of this notice in the Quebec Official Gazette.The Bonaventure Electricity Cooperative, Petitioner.By: OSCAR BUJOLD, President.By: SÉBASTIEN FORTIN, 38S83-52-4-o Manager. 3936 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 1951, Tome 86, N° 53 (P.G.10696-54) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le vingt-deux décembre 1954, les règlements de l'\"Asso-ciation de Bienfaisance Crémazie\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.\" Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le vingt-trois décembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38908-o JEAN BRUCHÉSI.(P.G.12911-54) bonnyville OlL & refining corporation (No Personal Liability) Règlement N° 6 Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Bonnyville Oil & Refining Corporation\" (No Personal Liability) (ici nommée la \"compagnie\") ce qui suit: 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentas, augmenté de trois (3) à onze (11) de manière que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de onze (11) directeurs.2° Cinq (5) directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3° Tous règlements résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à ice-lui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés de manière à donner effet à ce règlement.Décrété ce 6 décembre 1954.Certifié vraie copie.Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability) Par Le Président, 38909 L.C.CARROLL.Sherbrooke Indians Baseball Company Sommaire de Règlement 21 Après le paiement ou provision ayant été fait des dettes et du passif de la compagnie et après le 31ème jour de décembre, l'actif de la compagnie sera distribué en nature pro rata entre les actionnaires et ensuite la charte de la compagnie sera abandonnée.Aucun transfert d'actions sera enregistré après le 31ème jour de décembre.Les Procureurs de la Compagnie, WAINWRIGHT, ELDER, LAIDLEY, 38910-o LESLIE & BOURGEOIS.(P.G.12612-54) Rain ville Automobiles Limitée Règlement spécial \"B\" (Portant le nombre des directeurs de cette compagnie de trois (3) à quatre (4) : \"Qu'il soit permis de procéder à l'élection d'un quatrième directeur, à une assemblée spéciale des actionnaires, à être tenue immédiatement après l'approbation dudit règlement par l'autorité compétente, telle assemblée spéciale des actionnaires ayant été convoquée, en la manière prévue par les règlements de la compagnie.\" Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 38912-0 G.A.CHICOINE.(A.G.10696-54) Notice is given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary approved,,on the twenty-second day of December 1954, the bylaws of the \"Association de Bienfaisance Cré-mazîe\", and thus pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, the twenty-third day of December, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 38908 Under Secretary of the Province.(A.G.12911-54) Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability) By-law No.6 Be it enacted and it is hereby enacted as a bylaw of \"Bonnyville Oil & Refining Corporation\" (No Personal Liability) (herein called the \"Company\") as follows: 1.The number of directors of the Company be and the same is hereby increased from three (3) to eleven (11) so that the board of directors of the Company shall hereafter be composed of eleven (11) directors.2.Five (5) directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the Company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.Enacted this 6th day of December, 1954.Certified true copy.Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability) Per: L.C.CARROLL, 38909-o President.Sherbrooke Indians Baseball Company Siimmary of By-law 21 After payment or provision for the debts and liabilities of the Company and after December 31st, 1954, the assets of the Company will be distributed in kind pro rata amongst the shareholders and thereupon the Charter of the Company shall be surrendered.Nos transfers of shares shall be recorded after December 31st, 1954.Montreal, December 23rd, 1954.WAINWRIGHT, ELDER, LAIDLY, LESLIE & BOURGEOIS, 38910-o Attorneys for the Company.(A.G.12612-54) Rain ville Automobiles Limitée Special By-law \"B\" (Carrying the number of Directors of this company from three (3) to four (4) : \"That it be allowed to proceed to the election of a fourth Director, at a special meeting of its shareholders, to be held immediately after the approbation of the said by-law by a competent authority, such special meeting having been convened in the manner foreseen by the by-laws of the company.\" Certified true copy.G.A.CHICOINE, 38912 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 195A, Vol.80, No.58 3937 Avis est par les présentes donné par les soussignés que le Lieutenant-gouverneur en conseil a adopté, en date du 15 décembre 1954, un arrêté en conseil à l'effet de changer le nom de la municipalité du canton de Kilkenny, dans le comté de Montcalm, pour celui de \"municipalité de Saint-Calixte\", dans le comté de Montcalm.Conformément aux dispositions de l'article 48 du code municipal, ce changement de nom entre en vigueur à compter de la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.St.Calixte de Kilkenny, le 22 décembre 1954.Le Maire, EDOUARD BRIEN.Le Secrétaire-trésorier, 38913-0 PHILIPPE DUVAL.Notice is hereby given by the undersigned that the Lieutenant-Governor in Council adopted on December 15, 1954, an Order in Council to the effect that the name of the municipality of the township of Kilkenny, in the county of Montcalm, be changed to that of \"municipality of Saint Calixte\", in the same county.Pursuant to the provisions of article 48 of the Municipal Code, this change of name comes into force as from the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette.St.Calixte-de-Kilkennv, December 22nd, 1954.EDOUARD BRIEN, Mayor.PHILIPPE DUVAL, 38913 Secretary-Treasurer.(P.G.15450-52) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le seize décembre 1954, les règlements de \"L'Association des Spécialistes en Électronique de la Province de Québec\", tels qu'adoptés à l'assemblée générale spéciale tenue le 5 octobre 1954, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le dix-sept décembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38910-o JEAN BRUCHÉSI (A.G.15450-52) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved on December sixteenth, 1954, the by-laws of \"L'Association des Spécialistes en Électronique de la Province de Québec\", as adopted at the special general meeting held on October 5th, 1954, and such pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Secretary of the Province, December seventeen, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 3891G Under Secretarv of the Province.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"L'Association du Has Façonné de la Canada Hosiery Mills Ltd., Richmond, Que.\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le dix-sept décembre 1954.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Richmond, dans le comté de Richmond.Le Sous-secrétaire de la Province, 38929-0 JEAN' BRUCHÉSI.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"L'Association du Bas Façonné de la Canada Hosiery Mills Ltd., Richmond, Que.\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on December seventeenth 1954.The principal place of business of the said professional syndicate is at Richmond, county of Richmond.JEAN BRUCHÉSI, 3S929 Under Secretarv of the Province.Chartes \u2014 Abandon de Charters \u2014 Surrender of Sherbrooke Indians Baseball Company Sherbrooke Indians Baseball Company Avis est par les présentes donné que \"Sherbrooke Indians Baseball Company\" a l'intention de demander la permission d'abandonner sa charte en conformité avec la loi des compagnies de Québec.Montréal, le 23 décembre 1954.Les Procureurs de la Compagnie, WAINWRIGHT, ELDER, LAIDLEY, 38910-o LESLIE & BOURGEOIS.Notice is hereby given that \"Sherbrooke Indians Baseball Company\" intends to apply for leave to surrender its Charter in accordance with the Quebec Companies' Act.Montreal, December 23rd.1954.WAINWRIGHT, ELDER, LAIDLEY, LESLIE & BOURGEOIS, 3S910-o Attorneys for the Company.Avis de demande d'abandon de charte La compagnie \"Formcraft Fabrics Limited\", donne, par les présentes, avis qu'en vertu de la Loi des compagnies de Québec, elle s'adressera à l'Honorable Procureur général de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 27 décembre 1954.Le Procureur du requérant, 38932 B.BENNO COHEN.Notice of application for leave to surrender charter Under the Quebec Companies' Act, \"Form-craft Fabrics Limited\" hereby gives notice that it will make application to the Honourable the Attorney General of Quebec, for leave to surrender its charter.Montreal.December 27th, 1954.B.BENNO COHEN, 38932-0 Attorney for applicant. 3938 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 1951, Tome 80, N° 03 S.II.Wolff Corp.A MS Conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec, \"S.R.Wolff Corp.\" donne, par les présentes, avis qu'elle demandera la permission d'abandonner sa charte et la précision d'une date à compter de laquelle, la compagnie sera dissoute.Montréal.27 décembre 1954.Le Secrétaire, 3892G (Signé) RUTH WOLFF.S.R.Wolff Corp.NOTICE Under the provisions of the Quebec Companies' Act, \"S.R.Wolff Corp.\" hereby gives notice that it will make application for the acceptance of the Surrender of its charter, and to fix a date upon and from which the Company shall be dissolved.Montréal.December 27th.1954.(Signed) RUTH WOLFF.38926-0 Secretary.Curatelle publique Canada \u2014 Province de Québec District de Richelieu Successions vacantes de .Iules Trudeau, en son vivant cultivateur à Sainte-Julie, district de Richelieu, et de son épouse Dorilla Durochcr, de son vivant de Varennes, district de Richelieu.Le soussigné donne avis que ces successions ont été déclarées vacantes en vertu d'un jugement rendu le 18 décembre 1948 par un juge de la cour supérieure siégeant à Sorel dans le district de Richelieu, que, sous l'autorité de la Loi de la curatelle publique (9 Geo.VI, c.62), il est curateur d'office à ces successions, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers les successions et la preuve de toute réclamation contre elles.LE CURATEUR PUBLIC, 187, rue Stc-Catherine (ouest), 38904-o Montréal 1S.Public Curatorsliip Canada \u2014 Province of Quebec District of Richelieu Vacant estate of Jules Trudeau, in his lifetime a farmer of Saint Julie, district of Richelieu, and his wife Dorilla Durochcr.in her lifetime of Varennes, district of Richelieu.The undersigned gives notice that these estates hare been declared vacant in virtue of a jud-ment rendered December 18th, 1948, by a Judge of the Superior Court, sitting at Sorel, in the district of Richelieu, that he is, under authority of the Public Curatorship Act, (9 Geo.VI, C.62), Curator ex officio to these estates and that he shall receive, at the address nientionee below, the payment of all debts owing the estate and proof of all claims against said estates.PUBLIC CURATOR, 187, Saint-Catherine Street (West), 38904 \u2022 Montreal, 18.Demandes à la Législature Applications to Legislature AVIS NOTICE Avis est par les présentes donné que la Cor- Public notice is hereby given that la Corpora- poration des Pères Bénédictins de Saint-Benoit- tion des Pères Bénédictins de Saint-Benoit-du- du-Lac s'adressera à la Législature de la province Lac will apply to the Legislature of the Province de Québec à sa présente session pour demander of Quebec at its current session for the adoption l'adoption d'une loi modifiant son nom corpora- of a law modifying its corporate name, increas- tif, étendant ses pouvoirs et ceux de ses membres, ing its powers and those of its members, increasing étendant le territoire de la Municipalité de Saint- the territory of the Municipality of Saint-Be- Benoit-du-Lac et les pouvoirs de cette corpora- noit-du-Lac and the powers of this Corporation, tion.Saint-Benoit-du-Lac, le 3 novembre 1953.Saint-Benoit-du-Lac, 3rd November 1954.Le Procureur de la pétitionnaire.IVAN SABOURIN, 38780-50-4-o IVAN SABOURIN.38780-50-4-o Attorney for the petitioner.Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal Avis est, par les présentes, donné que la Corporation de \"Les Frères de la Charité\", corporation ayant son bureau-chef dans les cité et district de Montréal, fera une demande à la Législation de la province de Québec à sa présente session aux fins de faire adopter une loi pour augmenter son pouvoir de posséder des immeubles et pour d'autres fins.Montréal, ce 1er décembre 1954.Le Procureur de la requérante, 38781-50-4-o PHILIPPE FERLAND, C.R., Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal Notice is hereby given that the Corporation of \"Les Frères de la Charité\", corporation having its head office in the city aud district of Montreal, will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its present session for the purposes of adopting an act to increase its power to possess immoveables and for other purposes.Montreal, December 1st, 1954.PHILIPPE FERLAND, Q.C., 38781-50-4 Attorney for the petitioner. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 195L, Vol.86, No.53 3939 AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que la corporation de la ville d'Arthabaska, les commissaires d'écoles pour la municipalité du village d'Arthabaskaville, la corporation du village de Princeville, les commissaires d'écoles pour la municipalité du village de Princeville, la corporation du village de Warwick et les commissaires d'écoles pour le village de Warwick, tous du comté d'Arthabaska, s'adresseront «à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi aux fins suivantes: 1° Autoriser l'imposition d'une taxe de vente de 2% et d'une taxe d'éducation de 1% dans leurs territoires respectifs; 2° Additionner le produit des susdites taxes perçues dans les territoires sus-mentionnés et des taxes identiques perçues dans la ville de Victoriaville et en partager le total dans une proportion à être établie entre les différentes parties en cause; 3° Autoriser la ville d'Arthabaska, la corporation du ville de Princeville et la corporation du village de Warwick à emprunter respectivement des sommes de 875,000.00, 875,000.00 et 8150,000.00 pour expansion industrielle; 4° Autoriser la ville d'Arthabaska à effectuer pour fins de publicité, d'annonces, de représentation du maire et des échevins une somme n'excédant pas 81,000.00 annuellement; 5° Autoriser le conseil municipal d'Arthabaska à octroyer des deniers jusqu'à concurrence de 81,000.00 annuellement pour aider, dans la ville, certaines sociétés, organisations et œuvres sans but lucratif, et pour autres fins.Arthabaska, P.Q., IS novembre 1954.Les Procureurs des requérants, WALSH & MOISAN.L'A vocat-ad joint, 38803-50-4-o LOUIS LANGEAIS, Cit., AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que.la \"Commission des Ecoles catholiques de Montréal\" demandera à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, l'adoption d'une loi en vue d'accroître les pouvoirs de la Commission ayant trait à l'établissement ou à la modification d'assurances collectives ou autres en faveur de certaines personnes; d'amender les dispositions de sa charte relatives à son fonds de dotation; de modifier les dispositions de sa charte ayant trait au fonds de pension de ses employés; de déterminer la mise en vigueur de certains règlements municipaux à l'égard de la construction des écoles; d'autoriser, pour les fins de la taxe scolaire, l'inscription des mutations de propriétés au rôle de la cité de Montréal; et pour d'autres fins.Montréal, ce 10 décembre 1954.Le Procureur de la Commission des Écoles Catholiques de Montréal, 38829-51-4-0 GASTON POULIOT.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the corporation of the town of Arthabaska and the School commissioners for the municipality of the village of Arthabaskaville, the corporation of the village of Princeville, the School commissioners for the municipality of the village of Princeville, the corporation of the village of Warwick, and the School commissioners for the municipality of the village of Warwick, all of the county of Arthabaska, will apply to the Legislature of the province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act, for the following purposes: 1.To authorize the imposition of a sales tax of 2% «and of an Education tax of 1% in their respective territories; 2.To add the product of these collected taxes in the abovemcntioncd territories and of the same identical taxes collected in the town of Victoriaville, and to share the total thereof in the proportion to be made between the several parties in issue.3.To authorize the town of Arthabaska, the coqjoration of the village of Princeville and the corporation of the village of Warwick to borrow respectively the amounts of 875,000.00, 875,000.00 and 8150,000.00 for industrial expansion ; 4.To authorize the town of Arthabaska to grant annually a sum not exceeding 81,000.00 for publicity and advertisement purposes, and to pay entertainment expenses of mayor and councillors.5.To authorize the municipal council of Arthabaska to grant moneys to the amount of 81,000.00 annually to help certain non-profit associations, organizations and works, within the town; and for other purposes.Arthabaska, P.Q., november 18th, 1954.WALSH & MOISAN, Attorneys for the petitioners.LOUIS LANGLAIS, Q.C., 38803-50-4-o Associate Attorney.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the \"Montreal Catholic School Commission\" will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an act to increase the powers of the Commission concerning the establishment and the modification of group insurances or other insurances in favour of certain people; to amend the provisions of its charter concerning its endowment fund; to modify the provisions of its charter concerning the pension fund for its employees; to determine the coming into force of the municipal building by-laws with respect to the erection of schools; for the purpose of the school tax to authorize the inscription of the changes of ownership on the roll of the city of Montreal; and for other purposes.Montreal, December 10th, 1954.GASTON POULIOT, Attorney for the Montreal 38829-51-4-0 Catholic School Commission.Cité de Hull Avis est, par les présentes, donné que la \"cité de Hull\", s'adressera à la Législature de la Province de Québec, lors de sa présente session, pour obtenir l'adoption d'une loi spéciale, amendant sa charte, pour les fins suivantes: City of Hull Notice is hereby given that the \"city of Hull\" will present a petition to the Legislature of the Province of Quebec, at is present session, to obtain the adoption of a special law, amending its charter, for the following purposes: to amend its 3940 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 1951, Tome 86, N° 53 pour permettre l'amendement de son règlement de construction et de zonage sans referendum populaire durant sa première année d'existence; pour accorder des subventions dans certains cas particuliers; pour acquérir des immeubles pour fins industrielles; et pour d'autres fins.Hull, le 7 décembre 1954.Le Maire, (Signé) ALEXIS CARON.Le Greffier, (Signé) H.LÉON LEBLANC.Contresigné: Le Procureur de la cité de Hull, 38830-5l-4-o ROY FOURNIER.AVIS DE PÉTITION Avis est par les présentes donné que la cité de Rivière-du-Loup demandera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, l'adoption d'une loi amendant sa charte pour les fins suivantes: pour l'autoriser à emprunter une somme d'environ 8300,000.et à prêter le produit de cet emprunt à une compagnie de distribution d'énergie électrique, pour permettre à cette compagnie de construire une ligne de transmission électrique d'un point quelconque où se termine le réseau de cette compagnie jusqu'à la centrale électrique de la cité.Rivière-du-Loup, ce 15 décembre 1954.Le Procureur de la Cité de Rivière-du-Loup, 38884-52-4-0 JEAN-PAUL BÉRUBÉ, AVIS Avis par les présentes est donné que les Commissaires d'Écoles pour la municipalité scolaire du, village de Cap Chat, et les Commissaires d'Écoles pour la municipalité scolaire de Ste-Anne des Monts village, s'adresseront à la Législature de la province de Québec, à la présente session, pour obtenir la passation d'une Loi les autorisant à imposer une taxe spéciale de vente de 2%, dans leur territoire respectif.La commission scolaire du village de Cap Chat.Par le Secrétaire-trésorier, FRANÇOIS GAGNON.La Commission scolaire de Ste-Anne des Monts village.Par le Secrétaire-trésorier, LOUIS-PHILIPPE LANGELIER.38850-5 l-4-o AVIS PUBLIC Avis public est, par les présentes, donné que la ville de Dorval, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, la Loi 14 George VI, chapitre 120, en sus des matières décrites à l'avis du 22 novembre 1954, sur les matières suivantes: annexion du territoire de la corporation municipale de la paroisse de Côte de Liesse; et pour autres fins.Montréal, le 22 décembre 1954.Les Procureurs de la Ville de Dorval, LACROIX, VIAU & POUPART.38917-53-4-o AVIS PUBLIC Avis public est, par les présentes, donné (pie la ville de Pointe-Claire s'adressera à la Législa- building and zoning by-law without public referendum during its first year of existence; to make grants in certain cases; to acquire immovables for industrial purposes; and for other purposes.Hull, December 7th, 1954.(Signed) ALEXIS CARON, Mayor.(Signed) H.LÉON LEBLANC, City Clerk.Contersigned: ROY FOURNIER, 38830-51-4-o Attorney for the city of Hull.NOTICE OF PETITION Notice is hereby given that the city of Rivière-du-Loup will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter for the following purposes: to authorize the city to borrow a sum of about 8300,000 and to loan the proceeds of this transaction to an electric distribution company, in order that said company be permitted to construct an electric power line connecting the Company's system with the city's municipal electric power plant.Rivière du Loup, this December 15th, 1954.JEAN-PAUL BÉRUBÉ, Attornev for the City 38884-52-4 of Rivière-du-Loup NOTICE Notice is hereby given that the School Commissioners for the School Municipality of the village of Cap Chat, and the School Commissioners for the School municipality of St.Anne des Monts village, will apply to the Legislature of the province of Quebec, at its present session, to obtain the passing of an Act authorizing them to impose a special sales tax of 2%, in their respective territories.The School Commission of the village of Cap Chat, Per: FRANÇOIS GAGNON, Secretary-Treasu rer.The School Commission of St.Anne des Monts village, Per: LOUIS-PHILIPPE LANGELIER, Secretary-Treasurer.38850-51-4 PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the town of Dorval will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter, the Act 14 George VI, chapter 120, in addition to the purposes described in the notice of November 22th, 1954, for the following purposes: annexation of the territory of the municipal corporation of the parish of Côteflte Liesse; and for other purposes.Montreal, December 22nd, 1954.LACROIX, VIAU & POUPART, s Attorneys for the Town of Dorval.38917-53-4-0 PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the town of Pointe-Claire will apply to the Legislature of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 195A, Vol.86, No.53 3941 tu re de la province de Quebec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi, amendant sa charte, la loi 1 George V, chapitre 71, en sus des matières décrites à l'avis du 3 novembre 1954, sur les matières suivantes: imposer une taxe de vente de 2% pour fins municipales; et pour autres fins.Montréal, le 23 décembre 1954.Les Procureurs de la Ville de Pointe-Claire, LACROIX, VIAU & POUPART.38918-53-4-0 Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter, the Act 1 George V, chapter 71, in addition to the purposes described in the notice of November 3rd, 1954, for the following purposes: to impose a 2% tax for municipal purposes; and for other purposes.Montreal, December 23rd, 1954.LACROIX, VIAU & POUPART, Attorneys for the Town of Pointe-Claire.38918-53-4-0 Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des Prairies division d'enregistrement de Montréal.Avis est par le présenté donné que les lots 20-2 à 20-6, et les lots 21-2 à 21-48, 21-50 à 21-54, 21-57 à 21-61, 21-63 à 21-105, 21-108 à 21-112, 21-114 à 21-118, 21-121 à 21-150, 21-152 à 21-156, 21-158 à 21-162, 21-164 à 21-193, 21-196 à 21-200, 21-202 à 21-206, 21-209 à 21-252, 21-259 à 21-267, 21-269 à 21-273, 21-275 à 21-279, 21-281 à 21-326, 21-333 à 21-339, 21-344 à 21-346, 21-348 à 21-352, 21-355 à 21-378, 21-382 à 21-399, 21-401 à 21-426, 21-429 à 21-444, 21-446, 21-448 à 21-452, 21-454 à 21-480, 21-484 à 21-538, 21-540 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 13 avril 1954.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 38907-o AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel de la paroisse des Trois-Rivièrcs (maintenant partie de la municipalité de St-Michel-des-Forges) division d'enregistrement des Trois-Rivières.Avis est par les présente donné que les lots 178-170 à 178-185, 178-215 à 178-219, 180-1 à 180-4, 180-14 à 180-17, 180-20 à 1S0-39 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 19 novembre 1954.Le Déparlement des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 3S907-o AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg (cité de Québec) division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 726-48 à 726-57 et 726-60 à, 726-62 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 20 décembre 1954.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Department of Lands and Forests NOTICE Official cadastre of the parish of Rivière-des-Prairies registration division of Montreal.Notice is herebv given that lots 20-2 to 20-6, and lots 21-2 to 21-48, 21-50 to 21-54, 21-57 to 21-61, 21-63 to 21-105.21-108 to 21-112, 21-114 to 21-118, 21-121 to 21-150.21-152 to 21-156, 21-158 to 21-162, 21-164 to 21-193, 21-196 to 21-200, 21-202 to 21-206, 21-209 to 21-252, 21-259 to 21-267, 21-269 to 21-273, 21-275 to 21-279, 21-281 to 21-326.21-333 to 21-339, 21-344 to 21-346, 21-348 to 21-352, 21-355 to 21-378, 21-382 to 21-399, 21-401 to 21-426, 21-429 to 21-444, 21-446, 21-448 to 21-452, 21-454 to 21-480, 21-484 to 21-538 and 21-540 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, April the 13th, 1954.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 38907-o Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the parish of Three-Rivers (now part of the municipality of St.Michel-des-Forges) registration division of Three-Rivers.Notice is herebv given that lots 17.8-170 to 178-185, 178-215 to 178-219, 180-1 to 180-4, 180-14 to 180-17, 180-20 to 1.80-39 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, November the 19th.1954.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 3S907-o Deputy-Minister.NOTICE Official cadastre of the parish of Charlesbourg (city of Quebec) registration division of Quebec.Notice is hereby given that lots 726-48 to 726-57 and 726-60 to 726-62 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, December 20th.1954.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, Le Sous-ministre, AVILA BÉDARD, 3S907-o AVILA BÉDARD.38907-o Deputy Minister. 3942 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SI décembre 1954, Tome 86, N° 58 1\\ inistère des Finances A ssurances Loi des Assurances de Québec AVIS Les soussignés, Laurent Labelle, industriel, domicilié au N° 2785 Chemin Ste-Catherine, Montréal; Paul-Emile Ménard, gérant, domicilié au N° 359 boulevard St-Joseph est, Montréal; Henri Carcan, comptable, domicilié au N° 2925, boulevard Graham, ville Mont-Royal; J.-Edouard Jeannotte, notaire, domicilié au N° 3575 rue Sherbrooke est, Montréal; Jean Trudel, avocat, conseil en loi de la Reine, domicilié au N° 3503.rue Addington.Montréal, donne avis qu'ils ont l'intention de s'adresser au Lieutenant-gouverneur en conseil, le priant de les constituer en corporation de compagnie d'assurance, aux fins de transiger les groupes suivants d'assurance et de réassurance: contre les accidents, d'automobiles, d'aviation, contre le vol avec ou sans effraction, de crédit, contre les explosions, contre le feu, contre le faux, de garantie, contre la grêle, industrielle, responsabilité publique, de navigation intérieure, des transports intérieurs, sur le bétail, maritime océanique, contre le bris de glace, contre la maladie, contre les défectuosités dans les arrosoirs automatiques, sur les chaudières à vapeur, contre les cyclones, contre l'intempérie, ou tout autre groupe d'assurance ou de réassurance, excepté l'assurancé-vie, avec siège social en la cité de Montréal, au capital-actions de $500,-000.00 divisé en 5,000 actions de $100 chacune, le tout en conformité de la loi des assurances de Québec (S.R.Q.19-11, chapitre 299).Le nom de la compagnie sera: \"La Compagnie d'Assurance du Club des Automobilistes de Montréal\".Montréal.20 décembre 1954.LAURENT LABELLE, PAIL-ÉMILE MÉNARD, HENRI GAREAU, J.-ÉDOUARD JEAN N 0'IT K.38919-53-4-0 JEAN TRUDEL.Avis de nomination d'agent principal Avis est donné par les présentes que \"National Trust Company Limited\", dont le siège social est à Toronto, Ontario, à révoqué la nomination de monsieur T.VY.Hodgson à titre d'agent principal de la compagnie aux fins de recevoir la signification des procédures dans la Province, et le 23 décembre 1954.a nommé aux mêmes fins monsieur E.H.Hecney, 225 ouest, rue St-Jacques, Montréal, P.Q.Donné au bureau de l'inspecteur des compagnies de fidéicommis, Ministère des finances, 1954.Pour le Ministre des finances de la Province, GEORGES LAFRANCE, Inspecteur des compagnies de fidéicommis.38931-0 Department of Finance Insurances Quebec Insurance Act NOTICE The undersigned, Laurent Labelle, industrialist, residing at No.2875 St.Catherine Road, Montreal; Paul Emile Ménard, manager, residing at No.359 St.Joseph Boulevard, east, Montreal; Henri Gareau, accountant, residing, at No.2925 Graham Boulevard, town of Mount Royal; J.Edouard Jeannotte, notary, residing at No.3575.Sherbrooke Street, east, Montreal; Jean Trudel, advocate.Queen's Counsel, residing at No.3503.Addington Street, Montreal, give notice that they intend applying to the Lieute- a nant-Govcrnor in Council, praying him to incorporate them as an insurance company, for the purpose of transacting one of the following groups of insurance and reinsurance: accident, automobile, aviation, larceny, housebreaking or burglary, credit, explosion, fire, forgery, quarantee, hail, industrial, public liability, inland marine, inland transportation, livestock, ocean marine, plate glass, sickness, spinklcr leakage, steam boiler, tornado, weather, or any other class of insurance or reinsurance, save and except life insurance, with head office in the city of Montreal, with a share capital in the amount of 8500,000.00 divided into 5,000 shares of 8100 each, all of which pursuant to the Quebec Insurance Act (R.S.Q.1941, chapter 299).The name of the company shall be: \"La Compagnie d'Assurance du Club des Automobilistes de Montréal\".Montreal, December 20th, 1954.LAURENT LABELLE, PAUL EMILE MÉNARD.HENRI GAREAU, J.EDOUARD JEANNOTTE.919-53-4 JEAN TRUDEL.Notice of appointment of chief agent Notice is hereby given that \"National Trust Company Limited\", whose head office is situate at Toronto, Ontario, has revoked the appointment of Mr.T.W.Hodgson as chief agent in this province for the purpose of receiving service of process, and for the same purpose has appointed, on the 23rd of December 1954, Mr.E.H.Heenev, 225 St.James Street west, Montreal, P.Q.' * Given at the office of the Inspector of trust companies, Department of Finance, the 28th of December 1954.\u2022 For the Minister of Finance, of the Province, GEORGES LAFRANCE, Inspector of Trust Companies.38931-0 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December S 1st, 195A, Vol.86, No.53 3943 Proclamations Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION li'Assistant-procureur ( A TTENDU qu'une de-gênêral, \\ mande Nous a été C.E.CANTIN.( faite à l'effet de détacher le territoire ci-après décrit de la municipalité de la paroisse de Saint-André-Avellin, dans le comté municipal de Papineau, et de l'annexer à la municipalité du canton de Ripon, dans le môme comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 15 décembre 1954, portant le numéro 1241, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons, par les présentes: Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans la seigneurie de la Petite-Nation, comprenant les lots 489, 490, 491, 492 et 493 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-André-Avellin, ainsi qu'une partie du lac Simon et de la rivière Petite-Nation et tous les chemins, ou partie d'iccux, le tout délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne ouest du lot -190.avec la rive du lac Simon; de là.successivement, une ligne perpendiculaire à la rive du lac jusqu'à l'axe dudit lac; ledit axe, en le suivant vers l'est et vers le sud, et l'axe de la rivière Petite-Nation, en passant au nord de l'île désignée sous le numéro du cadastre 349, jusqu'au prolongement de la ligne ouest du lot 493; ledit prolongement, ladite ligne ouest du lot 493 et la ligne ouest des lots 492, 491 et 490 jusqu'au point de départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché fie la municipalité de la paroisse de Saint-André-Avellin, dans le comté municipal de Papineau, et sera annexé à la municipalité du canton de Ripon, dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent con- Proclamations Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern.Greeting : PROCLAMATION C.E.Cantin, / YWTIEREAS a request has Deputy Attorneys |)CCU presented to Us General.\\ for the purpose of detaching the territory hereinafter described of the municipality of the parish of Saint-André-Avellin, in the municipal county of Papineau, to annex it to the municipality of the township of Ripon in the same municipal county; Whereas all the formalities prescribed by law have been observed; Whereas it is expedient to grant the said request; Whereas in virtue of section 42 of the Municipal Code, the present proclamation shall enter into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree dated December 15th, 1954 bearing number 1241 and pursuant to the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, by these presents, That the following territory, to wit: A territory situate in the seigniory of \"la Petite-Nation\", comprising lots 489, 490, 491, 492 and 493 of the official cadastre of the parish of Saint-André-Avellin, as well as a part of Lake Simon and of the River \"Petite-Nation\" and all roads, or part thereof, the whole outlined as follows: starting from the point of intersection of the westerly line of lot 490 with the bank of Lake Simon; thence, successively, a perpendicular line with the bank of the lake to the axis of the said lake; the said axis, by following it towards the cast and towards the south, and the axis of the River \"Petite-Nation\", passing North of the island designated under cadastral number 349, to the prolongation of the westerly line of lot 493; the said prolongation, the said westerly line of lot 493 and the westerly line of lots 492, 491 and 490 to the starting point; which territory, shall, from and after January first, following the date of publication of the present proclamation in the Quebec Official Gazette, detached from the municipality of the parish Saint-André-Avellin, in the municipal county of Papineau, and shall be annexed to the municipality of the township of Ripon, in the same municipal county.That the present proclamation shall enter into force on the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are 3944 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 1954, Tome 86, A70 58 cerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.Ex foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin1: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CP., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-deuxième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre.Le Sous-secrétaire de la Province, 38903-o JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION VAssistant-procureur ( A TTENDU qu'une de-génêral, ) mande Nous a été C.E.Cantin.j faite à l'effet de détacher ' le territoire ci-après décrit de la municipalité de East-Broughton, dans le comté municipal de Beauce, et de l'ériger en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de East-Broughton-Station\", dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un 1 décret en date du 15 décembre 1954, portant le numéro 1241, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans le canton de B rough-ton, faisant actuellement partie de la municipalité de East-Broughton, comprenant, en référence au cadastre officiel du canton de B rough-ton, les lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, rues, ruelles, emprise de chemin de fer, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection du côté nord-est du chemin de front du rang VIII avec la ligne nord-ouest du lot 13-G, rang VIII; de là, passant successivement par les lignes suivantes: la ligne nord-ouest des lots 13-G, 13-F, 13-E, 13-D, 13-C, 13-B et 13-A.rang VII; la dernière prolongée à travers le chemin de front du rang VII; la ligne nord-ouest des lots 13-B, 13-A, rang VI et 13-B, rang V; la ligne nord-est des hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed: Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this twenty-second day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four, and in the third year of Our Reign.By Command, JEAN BRUCHÉSI, 38903 Under Secretary of the Province.Canada Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.SJ ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern, Greeting: PROCLAMATION C.E.Cantin, IVWTIEREAS We have been Deputy Attorney ) ?V requested to the effect General.\\ that the territory hereinafter ' described be detached from the municipality of East Broughtom, in the municipal county of Beauce, and erected into a separate municipality, under the name of \"Village Municipality of East Broughton Station, in the same municipal county; Whereas the formalities prescribed by law in this connection have been complied with; Whereas it is expedient that this request be granted; Whereas pursuant to article 42 of the Municipal Code, this proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree dated December 15th, 1954, bearing number 1241, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact.That the following territory, to wit: A territory situate in the township of Broughton, actually forming part of the municipality of East Broughton, comprising, with reference to the official cadastre of the township of Broughton, lots with the present and future subdivisions as well as roads, streets, lanes, railroad right-of-way, streams or parts thereof included within the following boundaries, to wit: commencing at the point of intersection of the northeast side of the road fronting range VIII with the line northwest of lot 13-G, range VIII; thence, passing successively by the following lines: the northwest line of lots 13-G, 13-F, 13-E, 13-D, 13-C, 13-B and 13-A, range VII; the latter extending across the road fronting range VII; the northwest line of lots 13-B, 13-A, range VI and 13-B, range V; the northeast line of lots QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1954, Vol.86, No.53 3945 lots 13-B, 14-B, 15-A et 15-B, rang V; la ligne sud-est du lot 15-B, rang V; la ligne separative des rangs V et VI en allant vers le sud-est; la ligne sud-est du lot 15-A, rang VI; le côté nord-est du chemin de front du rang VII en allant vers le sud-est jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 15-A, rang VII; ledit prolongement et ladite ligne sud-est du lot 15-A, rang VII; la ligne sud-est du lot 15-C, rang VII et enfin le côté nord-est du chemin de front du rang VIII limitant les lots 15-B, 14-E, 14-D, 14-B et 13-G du rang VII jusqu'au point de départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché de la municipalité de East-Broughton, dans le comté municipal de Beauce, et sera érigé en une municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de East-Broughton-Station\", dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, O.P., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-deuxième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 38903-o JEAN BRUCHÉSI.13-B, 14-B, 15-A and 15-B, range V; the south\" east line of lot 15-B, range V; the dividing line of ranges V and VI running southeasterly, the southeast line of lot 15-A, range VI; the northeast side of the road fronting range VII, running southeasterly, as far as the extension of the southeast line of lot 15-A, range VII; the said extension and said southeast line of lot 15-A, range VII; the southeast line of lot 15-C, range VII, and finally the northeast side of the road fronting range VIII bounding lots 15-B, 14-E, 14-D, 14-B and 13-G, range VII as far as the point of commencement ; which territory shall be, as from the first day of January following the date of publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, detached from the municipality of East Broughton, in the municipal county of Beauce, and erected into a separate municipality, under the name of \"Village Municipality of East Broughton Station\", in the same municipal county.That the proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal Our Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec., this twenty-second day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four and in the third year of Our Reign.By Command, JEAN BRUCHÉSI, 38903 Under Secretarv of the Province.Sièges sociaux Head Offices Colonie de Vacances du Sacré-Coeur Avis de changement d'adresse Colonie de Vacances du Sacré-Coeur Not ice of change of local ion Avis est par les présentes donné que la Colo- Notice is hereby given that the \"Colonie de nie de Vacances du Sacré-Cœur, incorporé par Vacances du Sacré-Cœur\", incorporated by lettres patentes le 12 juillet 1941.et ayant son letters patent dated -Inly 12th, 1941.having its bureau principal à 4094 rue Rivàrd Montréal, head office at 4094 Rivard Street Montreal, has est déménagée à 122 ouest, boulevard St-Joseph, moved said office to 122 St.Joseph Boulevard» Montréal.West, Montreal.Montréal, le 1er décembre 1954.Montreal, December 1st, 1954.(Sceau) Le Secrétaire, (Seal) DENYSE 'HAREL, 3S905-o DENYSE HAREL.38905 Secretary.Avis est, par les présentes, donné, que la compagnie \"Durochcr Automobiles Ltd\", constituée en corporation par lettres patentes le septième jour de décembre 1954, a établi son bureau et siège social à 2255 ouest, rue Notre-Dame, Lachine, dans le district de Montréal, province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Notice is hereby given that \"Duroeher Automobiles Ltd\", company incorporated by letters patent bearing the date of December seventh, 1954, has established its office at Lachine, at No.2255 Notre-Dame Street west, in the district of Montreal, Province of Qiebec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company. 3946 GAZETTE OFFICIELLE DE 01 'ÉliEC, Québec, 31 décembre 1954, Tome SU, N° 53 Donné à Montréal, ce 20ùnic jour de décembre Dated at Montreal, this 20th day of Decem- 1954.her, 1954.Duhocher Automobiles Ltd, Durocher Automobiles Ltd, (Sceau) Par le Président, (Seal) per: CLAUDE DUROCHER, 38930-o CLAUDE DUROCHER.38930-o President.AVIS Avis est donné que \"Salon Cendrillon Ltée\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 17 novembre 1954, et ayant son siège social à Rouyn, a établi son bureau principal au numéro 148 de l'avenue Principale, dans cette ville.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté à Rouyn, ce 25 novembre 1954.Le Secret a irc-t résorier, 38914-o RAYMOND BRUN ET.AVIS Avis est donné que \"Rouanda Sable & Gravier Ltée\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 4 novembre 1954, et ayant son siège social à Rouyn, a établi son bureau dans ladite cité.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Rouyn, ce 24 novembre 1954.Le Secrétaire-trésorier, 38928-0 * DON AT DÉSILETS.NOTICE Notice is hereby given that \"Salon Cendrillon Ltée\" incorporated by letters patent on the 17th day of November 1954, and having its head office in Rouyn, has established its office at 148 Main Street, therein.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Rouvn, this 25th day of November, 1954.RAYMOND BR UN ET, 3S914-o Secretary-Treasurer.NOTICE Notice is hereby given that \"Rouanda Sand & Gravel Ltd\" incorporated by letters patent on the fourth day of November 1954, and having its head office in Rouyn, has established its office therein.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Rouyn, this 24th dav of November 1954.DON AT DÉSILETS, 3S928-0 Secretary-Treasurer.Soumissions Province de Québec Les commissaires d'écoles protestantes POUR LA MUNICIPALITÉ DE StE-ThÉRESE (Comté de Terrebonne) Avis public est par les présentes donné (pie des soumissions cachetées et enofossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Théo.D.Monk, secrétaire-trésorier, 909 Chemin Grande-Côte, Rosemère, comté de Terrebonne, jusqu'à 8.30 heures p.m., mardi, le 18 janvier 1955, pour l'achat de S306,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles protestantes pour la municipalité de Ste-Thérèse, comté de Terrebonne, datées du 1er décembre 1954 et remboursables par séries du 1er décembre 1955 au 1er décembre 1974 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4%% par année payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 5 juin 1954, telle que modifiée \u2014 Construction d'une école de quinze classes.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er février 1955.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 §306,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er décembre 1955.xj836.500.00 1er décembre 1956.xj$8,000.00 Tenders Province of Quebec The protestant school commissioners for the municipality of ste.thérèse (County of Terrebonne) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Théo.D.Monk, Secretary-Treasurer, 909 Grande-Côte Road, Rosemère, county of Terrebonne, until 8.30 o'clock p.m., Tuesday, January 18th, 1954, for the purchase of an issue of 8306,000.00 of bonds of the protestant school commissioners for the municipality of Ste.Thérèse, county of Terrebonne, dated December 1st, 1954 and redeemable serially from December 1st, 1955 to December 1st, 1974 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor more than 4)^% per annum, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated June 5th, 1954, as modified \u2014 Construction of a 15-classroom school.Only for the purposes of awarding the issue, computation of interest will be made as from February 1st, 1955.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 §306,000.00 \u2014 20 years Year Capital December 1st, 1955.x 836,500.00 December 1st, 1956.x 38,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, December 31st, 1951, Vol.80, No.53 3947 1er décembre 1957.x 39,500.00 1 er décembre 1958.x 41,000.00 1er décembre 1959.7,000.00 1 er décembre 1960.7,000.00 1er décembre 1961.7.500.00 1 er décembre 1962.8,000.00 1 er décembre 1963.8,000.00 1er décembre 1964.8.500.00 1er décembre 1965.9,000.00 1er décembre 1966.9.000.00 1er décembre 1967.9.500.00 1er décembre 1968.10,000.00 1 er décembre 1969.10.000.00 1er décembre 1970.10.500.00 1er décembre 1971.11.000.00 1er décembre 1972.11,500.00 1er décembre 1973.12.000.00 1er décembre 197-1.12.500.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $143,-979.68, accordé par le Secrétaire de la province et payable en quatre versements de S35.994.92 chacun, de 1955 à 1958 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Ste-Thérèse, comté de Terrebonne.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné clans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Ste-Thérèse, comté de Terrebonne.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles protestantes qui sera tenue mardi, le 18 janvier 1955, à 8.30 heures p.m., en l'école protestante de Rosemère, comté de Terrebonne.Les commissaires d'écoles protestantes se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Rosemère.(Comté de Terrebonne), ce 28 décembre 1954.Le Secrétaire-trésorier, THEO.D.MONK.909 Chemin Grande-Côte, Rosemère, (Comté de Terrebonne), P.Q.3S927-o Province de Québec La Commission- des écoles catholiques des Trois-Rivières (Comté de Trois-Rivières) Avis public est par les présentes donné (pic des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, J.-U.Grégoire, secrétaire-trésorier, 1243 rue Hart, Trois-Rivières, jusqu'à 5 heures p.m., lundi, le 17 janvier 1955, pour l'achat de §971,500.00 d'obligations de la Commission des écoles catholiques des Trois-Rivières, comté de Trois-Rivières, datées du 1er février 1955 et remboursables par séries du 1er février 1956 au 1er fé- December 1st, 1957.x 39,500.00 December 1st, 1958.x 41,000.00 December 1 st, 1959.7,000.00 December 1st, 1960.7,000.00 December 1 st, 1961 .7,500.00 December 1st, 1962.8,000.00 December 1st, 1963.8.000.00 December 1st, 1964.' S.500.00 December 1 st, 1965.9,000.00 December 1st.1966.9,000.00 December 1 st, 4967.9,500.00 December 1 st, 1968.10,000.00 December 1st, 1969.10,000.00 December 1st, 1970.10,500.00 December 1 st, 1971.\u2022 II .000.00 December 1 st.1972.11,500.00 December 1 st, 1973.12.000.00 December I st, 1974.12,500.00 The \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $143,979.68, granted by the Provincial Secretary and payable in four instalments of 835.994.92, each, from 1955 to 1958 inclusively, will be received and applied to the service of this ioan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Ste.Thérèse, county of Terrebonne.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or Ste.Thérèse, county of Terrebonne.The said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the prostestant school commissioners to be held on Tuesday evening, January 18th, 1955, at 8.30 o'clock p.m., at the protestant school commission of Rosemère, county of Terrebonne.The protestant school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Rosemère, (County of Terrebonne), this 28th of December, 1954.THEO.D.MONK, Secretary-Treasurer.909 Grande-Côte Road, Rosemère, (County of Terrebonne), P.Q.3S92?-o Province of Quebec The catholic school commission of Trois-Rivières (County of Trois-Rivières) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned J.U.Grégoire, Secretary-Treasurer, 1243 Hart Street, Trois-Rivières, until 5 o'clock p.m., Monday, January 17th, 1955, for the purchase of an issue of $971,-500.00 of bonds of the catholic school commission of Trois-Rivières, county of Trois-Rivières, dated February 1st, 1955 and redeemable serially from February 1st, 1956 to February 1st, in- 3948 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 195L, Tome 86, N° 53 vrier 1975 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4}^% par année payable semi-annuellement les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 30 juin 1952, telle que modifiée \u2014 $60,000.00 \u2014 agrandissement de l'école Chamberlain! N° 17 et achat de deux terrains.Résolution d'emprunt en date du 14 septembre 1953, telle que modifiée \u2014 S95.000.00 \u2014 agrandissement de l'école Marie-Immaculée.Résolution d'emprunt en date du 19 octobre 1953, telle que modifiée \u2014 $314,300.00 \u2014 construction de l'école St-Jean-de-Brébeuf.Résolution d'emprunt en date du 14 juin 1954, telle que modifiée \u2014 démolition, construction et réparations aux écoles Ste-Cécile, St-Jean-de-Brébeuf et Ste-Marguerite, etc.\u2014 $502,-200.00 Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er février 1955.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement\u2014 $971,500.00\u201420 ans Année Capital 1er février 195\"6.x $110,000.00 1er février 1957.x 115,000.00 1er février 1958.x 121,000.00 1er février 1959.x 126,000.00 1er février 1960.22,000.00 1er février 1961.23,000.00 1er février 1962.23,500.00 1er février 1963.25,000.00 1er février 1964.26,500.00 1er février 1965.27,500.00 1er février 1966.28,500.00 1er février 1967.30,000.00 1er février 1968.31,500.00 1er février 1969.32,500.00 1er février 1970.34,000.00 1er février 1971.36,000.00 1er février 1972.37,000.00 1er février 1973.39,000.00 1er février 1974.41,000.00 1er février 1975.42,500.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $439,157.66, accordé par le Secrétaire de la province et payable en quatre versements dont le premier de $109,789.43 et les trois autres de $109,789.41 chacun, de 1956 à 1959 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt._ L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Trois-Rivières.Le capital et les intérêts sont payables au bureau principal d'une banque à charte dans les cités de Montréal, Québec ou Trois-Rivières.Les obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 17 janvier 1955, à 5 heures clusively, with interest at a rate of not less than 3% or over 4^% per annum, payable semiannually on February 1st, and August 1st, of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan Resolution dated June 30th, 1952, as modified \u2014 $60,000.00 \u2014 extension to Chamber-land school No.17 and the purchase of two pieces of land.Loan Resolution dated September 14th, 1953, as modified \u2014 $95.000.00 \u2014 extension to Marie-Immaculée school.Loan Resolution dated October 19th, 1953, as modified \u2014 $314,300.00 \u2014 Erection of St-Jean-dc-Brébeuf school.Loan Resolution dated June 14th, 1954, as modified \u2014 demolish, construct and repaire following schools: Ste-Cécile, St-Jean-de-Brébeuf and Ste-Marguerite, etc.\u2014 $502,200.00 For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $971,500.00 \u2014 20 years Year Capital February 1st, 1956.x $110,000.00 February 1 st, 1957.x 115,000.00 February 1st, 1958.x 121,000.00 February 1st, 1959.x 126,000.00 February 1st, 1960.22,000.00 February 1st, 1961.23,000.00 February 1st, 1962.23,500.00 \" February 1 st, 1963.25,000.00 February 1 st, 1964.26,500.00 February 1st, 1965.27,500.00 February 1st, 1966.28,500.00 February 1 st, 1967.30.000.00 February 1st, 1968.31,500.00 February 1st, 1969.32,500.00 February 1st, 1970.34,000.00 February 1st, 1971.36,000.00 February 1st, 1972.37,000.00 February 1st, 1973.39,000.00 February 1st, 1974.41,000.00 February 1 st, 1975.42,500.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $439,157.-66 granted by the Provincial Secretary and payable in four instalments of the first in the amount of $109,789.43 and the three others S109.789.41 each, from 1956 to 1959 inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Trois-Rivières.Capital and interest are payable at the head office of a chartered bank in the cities of Montreal, Quebec or Trois-Rivières.The said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Monday, January 17th, 1955, at 5 o'clock QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December Slat, 105.',, Vol.80, No.53 3949 p.m., au bureau du secrétaire-trésorier, 1243 rue Hart, Trois-Rivières.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Trois-Rivières, (Comté de Trois-Rivières), ce 17 décembre 1954.Le Secrétaire-trésorier, J.-U.GRÉGOIRE.1243 rue Hart, Trois-Rivières, P.Q.3890G-o p.m.at the office of the Secretary-Treasurer, 1243 Hart Street, Trois-Rivières.The school commissioners are not bound to accept the highest or any of the tenders.Trois-Rivières.(County of Trois-Rivières), this December 17th, 1954.J.U.GRÉGOIRE, Secrctarv-Treasu rer.1243 Hart Street, Trois-Rivières, P.Q.3890(5 VENTES PAR SHËRIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES ET HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnes plus bas.SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is herebv given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI Province de Québec \u2014 District d'Abitibi Cour Supérieure, ( TV\\ME MARTINE AYOT-N° V-2634.< *-J TE DUMO N TI E R, (.ménagère de la ville de Ma-lartic, épouse séparée de biens de Armand Dumontier, et ce dernier, du même endroit pour assister son épouse; saisissant vs'DAME BRO-NIS LISS TOMKYVICH, fille majeure usant de ses droits, autrefois de la ville de Malartic, district' d'Abitibi, et maintenant de lieux inconnus; saisi.ABITIBI Province of Quebec \u2014 District of Abitibi Superior Court, / TV\\ME MARTINE AYOT-No.V-2634.< TE, DUMONTIER, \\ housewife, of the town of Malartic, wife separate as to property of Armand Dumontier, and the latter of the same locality to assist his wife; Distrainer vs DAME LISS TOMKYVICH, fille majeure making use of her rights, formerly of the town of Malartic, district of Abitibi.and now of unknown whereabouts: distrainc.AVIS DE VENTE Un emplacement situé dans la ville de Malartic, connu et désigné comme étant le lot numéro seize (16) de la subdivision du bloc deux (2) \u2014 (2-16) canton Fournière avec bâtisses dessus construites circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église de Malartic le SAMEDI QUINZE JANVIER 1955 à DEUX (2) heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, FERDINAND GERVAIS.Amos, le 4 décembre 1954.38789-50-2-o NOTICE OF SALE An emplacement situate in the town of Malartic, known and designated as being lot number sixteen (16) of subdivision of block two (2) \u2014 (2-16) Fournière township with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.To be sold at the church door of Malartic, SATURDAY, the FIFTEENTH day of JANUARY 1955 at TWO (2) o'clock in the afternoon.FERDINAND GERVAIS, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, December 4th, 1954.38789-50-2 BEAUCE Fieri Facias de Terris District de Québec St-Joseph de Beauce Cour Supérieure, l pRNEST BROCHU, culti-N° 75-028 < vateur et commerçant \\ de St-Henri, comté de Levis, contre NAPOLÉON CARBONNEAU de Ste-Marguerite, comté de Dorchester et BOULET & BOULET en leur qualité de syndics à ladite faillite de Napoléon Carbonneau, mis en cause, à savoir: Un terrain ou emplacement situé à Ste-Mar-querite, Dorchester, mesurant 50' de front sur 100' de profondeur, le tout plus ou moins, borné en front au terrain de veuve A.Drouin, en profondeur et du côté nord-ouest au terrain de l'emprunteur et du côté sud-est au terrain de l'Oeuvre et Fabrique de Ste-Marguerite, étant partie des lots Nos cent quatre-vingt-huit et cent quatre-vingt-neuf (partie 188 et partie 189) du cadastre officiel de Ste-Marguerite, BEAUCE Fieri Facias de Terris District of Quebec St.Joseph de Beauce Superior Court, ( \"PRNEST BROCHU.farm-No.75-028 < J-* er and merchant of St.I Henri, county of Levis, vs NAPOLÉON CARBONNEAU, of St.Mar-guérite, county of Dorchester, and BOULET & BOULET, in their capacity of trustees of the said bankruptcy, of Napoleon Carbonneau, mis-en-cause, to wit: A piece of land or emplacement situate at St.Marguerite, Dorchester, measuring 50' of frontage by 100' in depth, all of which more or less, bounded in front by the land of veuve A.Drouin, in depth and on the northwest side by the land of the borrower and on the southeast side by the land of l'Oeuvre et Fabrique de Ste-Marguerite, being part of lots number one hundred and eighty-eight and one hundred and eighty-nine (part 1S8 ami part 189) of the 3950 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 195A, Tome SO, N° 53 Dorchester, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale, en la paroisse de Ste-Marguerite de Dorchester, le VINGT-HUITIÈME jour de JANVIER prochain à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.S.POULIOT.St-Joseph de Beauce, 13 décembre 1954.38841-51-2-0 [Première insertion: 18 décembre 1954] [Seconde insertion: 31 décembre 1954] BEALHARNOIS Province de Québec \u2014 District de Beauhamois Cour de Magistrat, ( T\\ A.BARRINGTON, N° 4334.j J-A marchand, du village (, de Ormstown dit district, demandeur; vs Les Héritiers de HENRY VAIL-LANCOURT, en son vivant, du même lieu, défendeurs.Saisi comme appartenant auxdits défendeurs: Un emplacement situé dans la paroisse St-Malachie de Ormstown, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de ladite paroisse, comme étant les lots numéros treize et quatorze de la subdivision officielle du lot originaire numéro soixante-huit (N° GS-13 et 14), avec les bâtisses dessus const mites.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de St-Malachie d'Ormstown, comté de Châtcauguav, district de Beauhamois, SAMEDI, le QUINZIÈME jour de JANVIER 1955 à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, ERNEST POIRIER.Salaberry de Valleyfield, ce 6 décembre 1954.387S7-50-2-o Radford Canada \u2014 Province de Québec District de Bedford Cour Supérieure, ( T 'OFFICE DU CRÉDIT N° 579S.-L* AGRICOLE DU QUÉ-\\ BEC, demandeur; vs HENRI ST-GERMAIN, défendeur; et PHILIPPE A.JOLIN, mis en cause.Comme appartenant au défendeur.Une terre sise et situé dans le canton de Brome, connue et désignée comme étant les lots numéros six cent vingt-deux (022), six cent vingt-trois, (023) et six cent vingt-quatre (024) du cadastre, officiel du canton de Brome, avec maison et toutes autres bâtisses y édifiées.La juste moitié nord de la partie sud du lot numéro huit cent cinquante-huit (858) du cadastre, du canton de Brome, de la contenance (ladite partie de lot) de dix-huit acres en superficie plus ou moins bornée (ladite partie de lot) comme suit: A l'ouest par le chemin public, au nord par la moitié nord dudit lot N° 858; à l'est par le numéro 857 dudit cadastre et au sud par la partie, du lot numéro 858; sans bâtisses.Pour être vendu en bloc à la porte de l'église catholique de St-François-Xavier de Shefford, MERCREDI le DOUZE JANVIER 1955, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, A.ST.MARTIN.Palais de Justice, Sweetsburg, Que., ce 4 décembre 1954.38788-50-2-0 officiai cadastre of St.Marguerite.Dorchester, with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.To be sold at the door of the parochial church, in the parish of Ste-Marguerite de Dorchester, the TWENTY-EIGHTH day of JANUARY next at TEN o'clock in the morning.J.S.POULIOT, Sheriff's Office, Sheriff.St-Joscph dc Beauce, December 13th, 1954.38841-51-2 [First insertion: December 18th, 1954] [Second insertion: December 31st, 1954] BEAUHARNOIS Province of Quebec \u2014 District of Beauhamois Magistrate's Court, ( T\\ A.BARRINGTON, No.4334.< -LA merchant, of the vil-V lage of Ormstown, said district, plaintiff; vs The Heirs of HENRY VAILLANCOURT, in his lifetime, of the same place, defendants.Seized as belonging to the defendants: An emplacement situate in the parish of St.Malachic of Ormstown, known and designated ou the official plan and in the book of reference of the said parish, as being lots numbers thirteen and fourteen of the official subdivision of the original lot number sixty-eight (No.6S-13 and 14), with the buildings thereon erected.\" To be sold at the parochial church door of the parish of St.Malachie of Ormstown, county of Châtcauguav, district of Beauhamois, SATURDAY, the FIFTEENTH day of JANUARY, 1955, at TEN o'clock in the forenoon.ERNEST POIRIER, Sheriff's Office^ Sheriff.Salaberry de Valleyfield, December Gth, 1954.3S7S7-50-2 BEDFORD Canada \u2014 Province of Quebec District of Bedford Superior Court, ( fMJEBEC FARM CREDIT No.579S.¦{ v
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.