Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 24 (no 47)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1956-11-24, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 88, N° 47 3849 Vol.88, No.47 \t¦\t \t\tWÊÊÊ \t¦\t- Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 24 novembre 1956 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à*?l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc , sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazelle officielle de Qtiébec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, November 24th, 1956 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party snail then pay upon reception of his account and before the second insertion : otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe.Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 3850 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 24 7iovembre 1956, Tome 88, N° 47 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont, priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 260 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de !a Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502-1-52 Lettres patentes receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.Li the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties arc requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion : 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rale.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents eaelu Slips: 81.per dozen.Subscriptions: S7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure referstoour document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS.Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502-1-52 m Letters Patent (P.G.12998-56) Agences Silhouette Inc.Silhouette Agencies Inc.Avis est donné qh'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept septembre 1956, constituant, en corporation: Laurent Drouin, avocat, Gaétane Richer, sténographe, célibataire, et Marcel Drouin, agent, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme libraires et papetiers; exercer le commerce d'articles religieux et de fantaisie, de fournitures scolaires et de bureau, sous le nom de \"Agences Silhouette Inc.\u2014 Silhouette Agencies Inc.\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 1,000 actions d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept septembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(A.G.12998-56) Agences Silhouette Inc.Silhouette Agencies Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of September, 1956, incorporating: Laurent Drouin, advocate, Gaétane Richer, stenographer, unmarried, and Marcel Drouin.agent, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business of booksellers and stationers; deal in ecclisiastical and fancy articles, school and office supplies, under the name of \"Agences Silhouette Inc.\u2014 Silhouette Agencies Inc.\", with a total capital stock of 8100,000.divided into 1.000 shares of a par value of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of September 1051).P.TRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 24th, 1956, Vol.88, No.47 3851 (P.G.13061-56) Alliance Steel & Metal Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six septembre 1956, constituant en corporation: Lcon David Crestohl, conseil en loi de la Reine, Donald William Seal, tous deux avocats, Abraham Harold Crestohl, gérant et Harvey Cres tohl, étudiant, tous de Montréal, poulies objets suivants: Exercer le commerce d'acier, fer, cuivre, bronze, plomb, zinc, alliages et produits en métal, sous le nom de \"Alliance Steel & Metal Co.Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six septembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 13729 P.FKENETTE.(P.G.12945-56) Almar Mining Corporation Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre septembre 1956, constituant en corporation: John Austin.Murphy, c.r., Pierre Décary, tous deux avocats, Francis Joseph Dolan, comptable, Mildred Murphy, ménagère, et Eleanor Hart, secrétaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour dévouvrir des mines et des minerais, y compris des terrains et gisements d'huile et de gaz et les négocier, sous le nom de \"Almar Mining Corporation Ltd.\", (No Personal Liability), avec un capital total de 83.000,000, divisé en 3,000,000 (Tactions d'une valeur au pair de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre septembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 13729 P.FRENETTE.(P.G.13160-56) A.Nagine Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du neuf octobre 1950, constituant en corporation: Alesius Nagine, entrepreneur, Alexander Hiega, avocat et Joyce Regina Hiega, ménagère, tous de Beaurepaire, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux» démolition et réparation de bâtisses, sons le nom de \"A.Nagine Inc.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 37 Chemin Brentwood, Beaurepaire, district judiciaire de Montréal.(A.G.13061-56) Alliance Steel & Metal Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of September, 1956, incorporating: Leon David Crestohl, Queen's Counsel, Donald William Seal, both advocates, Abraham Harold Crestohl, manager, and Harvey Crestohl, student, all of Montreal, for the following purposes: To deal in steel, iron, copper, brass, lead, zinc, alloys and metal products, under the name of \"Alliance Steel & Metal Co.Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of September, 1956.P.FRENETTE, 43729-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12945-56) Almar Mining Corporation Ltd., (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Liuctenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth clay of September, 1956, incorporating: John Austin Murphy, Q.C., Pierre Dccary, both advocates, Francis Joseph Dolan, accountant, Mildred Murphy, housekeeper, and Eleonar Hart, secretary, all of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals including oil and gas lands and deposits and deal with the same, under the name of \"Almar Mining Corporation Ltd.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $3,000,000, divided into 3,000,000 shares of a par value of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The bead office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of September, 1956.P.FRENETTE, 43729-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13160-56) A.Nagine Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of October, 1956, incorporating: Alesius Nagine, contractor, Alexander Biega, advocate and Joyce Regina Biega, housewife, all of Beaurepaire, for the following purposes: To carry on the business of general contractors, demolition and repairs of buildings, under the name of \"A.Nagine Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 100 common shares of S100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 37, Brentwood Rd., Beaurepaire, judicial district of Montreal. 3852 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2A novembre 1966, Tome 88, N° A7 Daté du bureau du Procureur général, le neuf Dated at the office of the Attorney General, octobre 1956.this ninth day of October, 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 43729 P.FRENETTE.43729-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.13113-56) Anctil Development Limited Avic est donné cpTen vertu de la premiere partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente septembre 1956, constituant en corporation: Louis-René Hamelin, Jacques Anctil, avocats, tous deux de Montréal, et Roland Jarry, industriel, de Sainte-Dorothée, pour, les objets suivants: Exercer le commerce de foreurs, de chercheurs de mines et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Anctil Development Limited\", avec un \u2022 capital total de §40,000, divisé en 400 actions de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera 3441, rue Saint-Denis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente septembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.43729-0 P.FRENETTE.(P.G.12785-56) Association des Hôpitaux du Québec Inc.Quebec Hospital Association Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutehant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf octobre 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Paul-A.Crépeau, Jean-Baptiste Crépeau, avocats, et Pauline Rolland, secrétaire, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Stimuler .l'intérêt public dans la chose hospitalière; maintenir et améliorer la qualité des services hospitaliers; promouvoir entre établissements hospitaliers de la province un échange d'information et de personnel, sous le nom de \"Association des Hôpitaux du Québec Inc.\u2014 Quebec Hospital Association Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation est de S500.000.Le siège social de la corporation sera 3459, rue St-Dcnis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf octobre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(A.G.13113-56) Anctil Development Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of September 1956, incorporating: Louis René Hamelin, Jacques Anctil, advocates, both of Montreal, and Roland Jarry, industrialist, of Saint Dorothée, for the following purposes: To carry on the business of drillers, mine prospectors, and general building contractors, under the name of \"Anctil Development Limited\", with a total ccpital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 3441 Saint Denis Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of September 1956.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12785-56) Association des Hôpitaux du Québec Inc.Quebec Hospital Association Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of October, 1956, to incorporate as a corporation without share capital: Paul-A.Crépeau, Jean-Baptiste Crépeau, advocates, and Pauline Rolland, secretary, all three of Montreal, for the following purposes: To stimulate public interest in hospitalisation matters; maintain and improve hospital services; to promote the exchange of information and of personnel between hospital establishments in the Province, under the name of \"Association des Hôpitaux du Québec Inc.\u2014 Quebec Hospital Association Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 8500,000.The head office of the corporation will be at 3459 St-Denis Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of October, 1956.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(P.G.13184-56) Atomick Tire Sales & Repairs Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze octobre 1956, constituant en corporation : J.-Théo.Legault, fils, Elvin Legault, notaires, et Rita legault, secrétaire, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: , Faire affaires comme garagistes, sous le nom de \"Atomick Tire Sales & Repairs Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.(A.G.13184-66) Atomick Tire Sales & Repairs Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearipg \"date the eleventh nay of October, 1956, incorporating: J.Théo.Legault, junior, Elvin Legault, notaries, and Rita Legault, secretary, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers, under the name of \"Atomick Tire Sales & Repairs Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 24th, 1956, Vol.88, No.47 3853 Le siege social de la compagnie sera 7031, rue Norman ville, Montreal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze octobre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(P.G.13105-50) Avnior Chibouganiau Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf septembre 1950, constituant en corporation: Morris Goldenberg, éditeur, Ernest Lafontaine, procureur, Roberte Smith, secrétaire privée, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Avmor Chibouganiau Mines Limited'' (No Personal Liability), avec un capital total de 85,000,000 .divisé en 5,000.000 d'actions d'une valeur au pair de 81 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf septembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, \u202213729 P.FRENETTE.(P.G.12965-56) Bellemare Sports Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq octobre 1956, constituant en corporation: Paul-E.Bellemarre.marchand, Mme Hélène David-Bellemarre, ménagère, épouse séparée de biens dudit Paul-E.Bellemarre, et Jean Mailhot, ingénieur professionnel, tous trois de^ongueuil.pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de vêtements, d'articles de sport et de mercerie, sous le nom de \"Bellemare Sports Inc,\", avec un capital total de 840,000, divisé en 3,000 actions communes de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lon-gueuil, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq octobre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(P.G.12715-56) Buffet Raymond Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre octobre 1956, constituant en corporation: Réal Marcoux, avocat, Rita Dufresne, sténographe, célibataire, tous deux de Montréal, et Ronald Halpin, C.R., avocat, de ville St-Eustache, pour les objets suivants: Exploiter des salles publiques, hôtels et restaurants, sous le nom de \"Buffet Raymond Ltée\", The head office of the Company will be at 7631 Norman ville street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of October, 1956.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13105-56) Avmor Chibougamau Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of September, 1956, incorporating: Morris Goldenberg, publisher, Ernest Lafontaine, barrister, Roberte Smith, private secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Avnior Chibougamau Mines Limited\" (No Personal Liability), with-a total capital stock of $5,000,000, divided into 5,000,000 shares of a par value of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of September, 1956.P.FRENETTE, 43729-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12965-56) Bellemare Sports Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of October, 1956, incorporating: Paul-E.Bellemarre, merchant, Mrs.Hélène David-Bellemare, housewife, wife separate as to property of the said Paul-E.Bellemare, and Jean Mailhot, professional engineer, all three of Longueuil, for the following purposes: To carry on an industry and business, dealing in clothing, articles of sport and haberdashery, under the name of \"Bellemare Sports Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of S10 each and into 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Longueuil, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of October, 1950.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12715-56) Buffet Raymond Ltée , Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of October 1956, incorporating: Real Marcoux, advocate, Rita Dufresne, stenographer, unmarried, both of Montreal, and Ronald Halpin, Q.C., advocate, of the town of St.Eustache, for the following purposes: To operate public halls, hotels and restaurants, under the name of \"Buffet Raymond Ltée\" 3854 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2J, novembre 1956, Tome 88, N° A7 avec un capital divisé en 200 actions sans valeur au pair ou nominale et en 10 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera «à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre octobre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(P.G.13062-56) Canadian Wallboard Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix octobre 1956, constituant en corporation: Paul Szymanski, marchand, Daniel Kingstone, étudiant, de Montréal, et Alexander MacNab, constructeur, de Bedford, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux et fabriquer, et négocier des matériaux, fournitures, machinerie et équipement de construction, sous le nom de \"Canadian Wallboard Ltd.\", avec un capital-actions divisé en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair S100 chacune et 000 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à Mont réal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix octobre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant.43729 P.FRENETTE.(P.G.12483-56) Cell h ka Limitée Celluka Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept septembre 1956, constituant en corporation: Claude Benoît, Jean Brûlé, avocats, et Rolande Racette, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Sujet à la loi de Pharmacie de Québec, faire affaires comme pharmaciens en gros, sous le nom de \"Celluka Limitée \u2014 Celluka Limited\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 2.000 actions communes de 810 chacune et en 800 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(P.G.12838-56) Centre des Matériaux de Construction, Inc.Building Supply Center, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept septembre 1956, constituant en corporation: J.-Alfred Laflamme, industriel, Philippe Gavard, comptable, tous deux de Hull, et J.-Arthur Laflamme, Chef d'Escadrille, R.C.A.F., de St-Jean d'Iberville, pour les objets suivants: Exercer le commerce de matériaux de construction et faire affaires dorame constructeurs with a total capital divided into 200 shares without nominal or par value and 40 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of October 1956.P.FRENETTE, 47239 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13062-56) Canadian Wallboard Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of October, 1956, incorporating: Paul Szymanski, merchant, Daniel Kingstone, student, of Montreal, and Alexander MacNab, builder, of Bedford, for the following purposes: To carry on the business of general contractors and to manufacture and deal in building materials, building supplies, machinery and equipment, under the name of \"Canadian Wallboard Ltd.\", with a capital stock divided into 100 preferred shares of a par value of $100 each and into 000 shares having no nominal or par value.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of October, 1956.P.FRENETTE, 43729-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12483-56) Celluka Limitée Celluka Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of Spetember 1956, incorporating: Claude Benoit, Jean Brule, advocates, and Rolande Racette, secretary, having reached the age of majority and making use of her rights, all three of Montreal, for the following purposes: SubjecMo the Quebec Pharmacy Act ; to carry on business as wholesale druggists, under the name of \"Celluka Limitée \u2014 Celluka Limited\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 2.000 common shares of 810 each and 000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh dav of September.1950.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12838-56) Centre des Matériaux de Construction, Inc.Building Supply Center, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of September, 1956.incorporating: J.-Alfred Laflamme, industrialist, Philippe Gavard, accountant, both of Hull, and J.-Arthur Laflamme, Squadron Leader, R.C.A.F., of St.John's d'Iberville, for the following purposes: To carry on a business dealing in building material and to carry on as builders and general QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 2.',th, 1966, Vol.88, No.J,7 3855 ct entrepreneurs généraux eu construction, sous le nom «le \"Centre des Matériaux de Construction, Inc.\u2014 Building Supply Center, Inc.\", avec un capital divisé en 850 actions communes sans valeur au pair, et en 750 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Hull, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept, septembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(P.G.13064-56) Chez Sandra Inc.Avis est donne qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept septembre 1956, constituant ci corporation: Charles Brownstcin, de la ville île (nie St-Luc, Moses Moseovitch ct John Liber-tnan, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce de vêtements et articles vestimentaires pour dames, demoiselles et enfants, sous le nom de \"Chez Sandra Inc.\", avec un capital total de 875.000, divisé en 2.500 actions ordinaires d'une valeur au pair «le 810 chacune et 5,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège;social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 13729 P.FRENETTE.(P.G.13003-50) Columbia Investments Lid.Avis est donné *qu'en vertu de la première partie de la I of September 1950, incorporating: Sarto Founder, Gérard Huot, business men, and Jacques Langlois, industrialist, all of Granby, for the following purposes: Acquire immoveables, manage a club for golf, curling, and any other sports generally, under the name of \"Granby-St.Paul Golf & Country Club Inc.\", with a total capital stock of $200,-000, divided into 2.009 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General,' this twenty-ninth day of September 1950.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13100-50) Grande Côte Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of September, 1956, incorporating: Milton Lowen Klein, Arthur Bronstein, both advocates, and lown Christopher, secretary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a construction and improvement company, and to deal in building materials, under the name of \"Grande Côte Development Corp.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth dav of September.1950.P.FRENETTE, 43729-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12975-50) Grande He Scrap Yards Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of September, 1950, incorporating: Alfred Zimmerman, advocate, David Finestone, chartered Accountant, and Max Goldman, notary, all of Montreal, for the following purposes: To deal in all kinds of scrap iron, sera]) metal and related products of all kinds, under the name of \"Grande He Scrap Yards Inc.\", with a total capital stock of $-10,000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 200 preferred shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 2/,th, 1956, Vol.88, No.Jft 3863 Le siège social de la compagnie sera à Grande-Ile, Valleyfield, district judiciaire de Beaunarnois.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre septembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729 \u2022 P.FRENETTE.(P.G.13118-56) Giiilbuull & Moreau Limitée Avis est donné qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six octobre 1959, constituant en corporation: André Guilbault, René Moreau, de Montréal, et Lucien Guilbault, de Rivière-des-Prairies, tous trois commerçants, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'appareils, matériel, accessoires et fournitures de ferblanterie, de métal en feuilles et de fev forgé-, sous le nom de \"Guilbault & Moreau Limitée\", avec un capital total de $21,090, divisé en 210 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six octobre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(P.G.13072-56)' Harry Villeneuve Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf septembre 1950.constituant en corporation: J.-Bruno Deniers, comptable, Raymond La Roche, comptable agréé, et Harry Villeneuve, industriel, tous trois de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce de meubles, nouveautés de toutes sortes, du bois et autres matériaux, sous le nom de \"Harry Villeneuve Ltée\", avec un un capital total de 820,000, divisé eu 2,00!) actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 451, rue Racine.Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf septembre 1950.f/Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(P.G.13121-50) Hygrade Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier octobre 1950, constituant en corporation: Emil Zollman, constructeur, Isaac Piaset-ski, vendeur, Fajwiss Shapiro, peintre ct Max Goldman, notaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Hygrade Construction Co.Ltd.\", avec un capital total de $10.000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 0,076 rue Hutchison, Montréal, district judiciaire de Montréal.The head office of the company will be at Grand-He, Valleyfield, judicial district of Beau-harnois.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth dav of September, 1950.P.FRENETTE, 43729-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13118-50) Guilbault & Moreau Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of October, 1950, incorporating: Andre (iuilhault, René Moreau, of Montreal, and Lucien Guilbault, of Rivières des Prairies, all three merchants, for the following purposes: To carry on the business of and ileal in apparatus, materials, accessories and supplies in tin, sheet metal and wrought iron, under the name of \"Guilbault & Moreau Limitée\", with a total capital stock of $21,000, divided into 210 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of October, 1950.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13072-50) Harry Villeneuve Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of September 1950, incorporating: J.Bruno Deniers, accountant, Raymond La Roche, chartered accountant, and Harry Villeneuve, industrialist, all three of Chicoutimi, for the following purposes: To deal in furniture, novelties of every nature and tired lumber and other materials, under the name of \"Harry Villeneuve Ltée\".with a total capital stock of S20.000, divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 451 Racine Street, Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth dav of September, 1950.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13121-50) Hygrade Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of October, 1950.incorporating: Emil Zollman, builder, Isaac Piasetski.salesman, Fajwisz Shapiro, painter, and Max Goldman, notary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a construction company^under the name of \"Hygrade Construction Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 0,070 Hutchison Street, Montreal, judicial district of Montreal.' 3864 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 24 novembre 1956, Tome 88, N° 47 Daté du bureau du Procureur général, le premier octobre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729 P.FRENETTE.(P.G.12991-56) Industrie d'Argenson Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt septembre 1956, constituant en corporation: N.-Antonio Ally, industrial, Juliette Brassard Ally, ménagère, épouse dudit Antonio Ally, et Simone Ally, secrétaire, fille majeure, tous trois de Roberval, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de papier, matériel en papier, carton, les substituts, ingrédients et produits du papier et leurs constituants, sous le nom de \"Industrie d'Argenson Limitée\", avec un capital total de 875,000, divisé en 750 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Roberval, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le vingt septembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(P.G.12918-56) Jadan Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt septembre 1956, constituant en corporation: Gisèle Mercier, secrétaire, Jacques Morais, étudiant, tous deux de Montréal et Marc Leroux, notaire, de Ville Mont-Royal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, de construction et d'amélioration, sous le nom de \"Jadan Inc.\", avec un capital total de 8350,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune et 3,400 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729 P.FRENETTE.(P.G.12571-50) Ko-Kctte Novelty Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq octobre 1950, constituant en corporation: Jacques Leduc, avocat, Grace-Anne-Hayami, sténographe, célibataire, tous deux de Montréal, et Alexander John Campbell, avocat, c.r., de West-mount, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de marchandises sèches, fourrures, draps, bonnets et vêtements d'enfants, sous le nom de \"Ko-Kette Novelty Co.Ltd.\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 1,250 actions communes de 820 chacune et en 750 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq octobre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.Dated at the office of the Attorney General, this first day of October, 1950.P.FRENETTE, 43729-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12991-56) Industrie d'Argenson Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of September, 1956, incorporating: N.Antonio Ally, industrialist, Juliette Brassard Ally, housewife, wife of the said Antonio Ally, and Simone Ally, secretary, spinster, all three of Roberval, for the following purposes: To carry on the industry and business of paper, material in paper, cardboard, substitutes, ingredients and paper products and their components, under the name of \"Industrie d'Argenson Limitée\", with a total capital stock of $75,000, divided into 750 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Roberval, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of September, 1950.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12918-50) Jadan Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of September, 1950, incorporating: Gisèle Mercier, secretary, Jacques Morais, student, both of Montreal, and Marc Leroux, notary, of the town of Mount Royal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of ¦ \"Jadan Inc.\", with a total capital stock of $350,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and into 3,400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of September, 1950.P.FRENETTE, 43729-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12571-50) Ko-Kctte Novelty Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of October, 1950, incorporating: Jacques Leduc, advocate, Grace-Anne Hayami, stenographer, bachelor, both of Montreal, and Alexander John Campbell, advocate, Q.C., of Westmount, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in drygoods, furs, fabrics, and children's bonnets and clothing, under the name of \"Ko-Kette Novelty Co.Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,250 common shares of $20 each and into 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of October, 1956.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 2>,th, 1056, Vol.88, No.47 3805 (P.G.13014-56) La Compagnie de Hois Youville Ltée Youville Lumber Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes,en date du premier octobre 1956.constituant en corporation: Henri Renaud, comptable.Roland Dom-pierre, principal, tous deux de Hull, Ovide Proulx, principal, de Eastview, Ontario, Fern and Larose, notaire, de Pointc-Gatineau, et Jean-Paul Le-cours, aviateur, d'Ottawa, pour les objets suivants: Exercer le commerce de bois, de matériaux de construction, d'articles de ferronnerie et de meubles en général, sous le nom de \"La Compagnie de Bois Youville Ltée \u2014 Youville Lumber Company Ltd.\", avec un capital total de 825,000, divisé en 2,500 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Pointe-Gatineau, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le premier octobre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(P.G.12978-56) La Compagnie de Téléphone de St.Henri de Mascouche Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre septembre 1950, constituant en corporation: Pierre-Charles Lacaillc, avocat, Lucille Taillefer et Claire Chartrand, secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter une ou plusieurs lignes de téléphone, avec embranchements, «lans les comtés de I/'Assomption, de Terrebonne et de Montcalm, sous le nom «le \"La Compagnie de Téléphone de St.Henri de Mascouche Ltée\", avec un capital total de 810,000, divisé en 3.500 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le 810 Chacune et en 5.000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera rue Sainte-Marie, Saint-Henri-de-Mascouche, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43720-o ' P.FRENETTE.(P.G.12560-50) La Laiterie Victoria Inc.Victoria Dairy Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec «les lettres patentes, en «late \u2022 lu vingt-quatre septembre 1950, constituant en corporation: François-J.Basticn, C.A., «le Saint-Lambert, Mario Du Mesnil.avocat, Roland Savignac, notaire, «le Montréal, et Jean Tellier, avocat, de Wcstmount, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce du lait et «le ses sous-produits ainsi «pie la vente des œufs, sous le nom de \"La Laiterie Victoria Inc.\u2014 Victoria Dairy Inc.\", avec un capital total de $200,000, divisé en 1,750 actions privilégiées «le $100 chacune et en 1,000 actions ordinaires de $25 chacune.(A.G.13044-50) La Compagnie de Bois Youville Ltée Youville Lumber Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the first day of October, 1950, incorporating: Henri Renaud, accountant, Roland Dompierre, principal, both of Hull, Ovide Proulx, principal, of Eastview, Oidario, Fernand Larose, notary, of Pointe-Ga-tineau, and Jean-Paul Lccours, aviator, of Ottawa, for the following purposes: To carry on the lumber business, deal in building materials, articles of ironware an«l in furniture generally, under the name of \"La Compagnie de Bois Youville Ltée \u2014 Youville Lumber Company Ltd.\", with a total capital stock of $25.000, divided into 2,500 shares of $10 each.The head office of the company will be at Pointe-Gatineau, judicial district of Hull.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of October, 1959.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12978-50) La Compagnie de Téléphone de St.Henri de Mascouche Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the fourth day of September, 1950, incorporating: Pierre-Charles Lecaille, advocate, Lucille Taillefer, and Claire Chartrand, secretary, bachelors, of Montreal, for the following purposes: To operate one or several telephone lines with branches in the counties of L'Assomption, Terrebonne and Montcalm, under the name of \"La Compagnie de Téléphone de St.Henri «le Mascouche Ltée\", with a total capital stock of $10,000, divided into 3,500 preferred shares of a par value of $10 each and into 5,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Sainte-Marie Street, Saint-Henri-de-Mascouche, judicial district of Jolictte.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of September, 1950.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12500-50) La Laiterie Victoria Inc.Victoria Dairy Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of September 1950, incorporating: Francois J.Basticn, C.A., of Saint-Lambert, Mario Du Mesnil.advocate, Roland Savignac, notary, of Montreal, and Jean Tellier, advocate of Westmount, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in milk and its by-products as well as the sale of eggs, under the name of \"La Laiterie Victoria Inc.\u2014 Victoria Dairy Inc.\".with a total capital Stock of $200.000.divided into 1.750 preferred shares of $100 each and into 1,000 common \u2022 shares of $25 each. 3866 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 24 novembre 1956, Tome 88, N° 47 Le siège social de la compagnie sera à 431, rue Bute, Saint-Lambert, \u2022 district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre septembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-a P.FRENETTE.(P.G.12552-56) Landry Auto Service Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre septembre 1956, constituant en corporation: J.-B.Landry, rentier, Léon Lan-Landry et Gérard Landry, garagistes, tous trois de Ste-Hélène.Kamouraska, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'automobiles et de véhicules de toutes sortes; faire affaires comme garagistes et exercer le commerce du transport, sous le nom de \"Landry Auto Service Inc.\".avec un capital total de $50,000, divisé en 100 actions privilégiées de 8100 chacune et en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Hélène, district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant,\u2022 43729-q P.FRENETTE.The head oflice of the company will be at 431 Bute St., Saint-Lambert, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of September, 1950.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12552-50) Landry Auto Service Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of September 1950, incorporating: J.-B.Landry, annuitant, Léon Landry and Gérard Landry, garage-keepers, all three of St.Hélène, Kamouraska, for the following purposes: To deal in automobiles and vehicles of every nature and kind; carry on business as garage-keepers and deal in transportation, under the name of \"Landry Auto Service Inc.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 100 preferred shares of 8100 each and 400 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at Saint Hélène, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth dav of September, 1956.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12522-56) L'Anneau-Centre d'Orientation des Foyers Canadiens Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre octobre 1956.constituant en corporation: Roland-G.Chauvin, avocat, de Montréal, Pierre «le Grandpré, avocat, et Yolande Robi-chaud, secrétaire, tous deux de Saint-Lambert, pour les objets suivants: Constituer un centre catholique d'orientation, de rencontre, d'étude pour les personnes désireuses de s'éclairer au sujet des problèmes familiaux ou matrimoniaux, sous le nom de \"L'An-neau-Çentre d'Orientation des Foyers Canadiens Inc.\", avec un capital total de 85,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 373, Carré Saint-Louis, Montréal, district judiciaire de .M oui réal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre octobre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(P.G.13151-56) Lanza Steak House Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf octobre 1956, constituant en corporation: Theobald Plamondon, Joseph Lanza, administrateurs, tous deux de Montréal et Marcel Champagne, comptable, de Pointe-aux-Trembles, pour les objets suivants: Promouvoir, établir, conduire, entretenir un a restaurant, café, grill, sous le nom de \"Lanza Steak House Ltd.\", avec un capital total de (A.G.12522-56) L'Anneau-Centre d'Orientation des Foyers Canadiens Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of October 1956, incorporating: Roland G.( hauvin.advocate, of Montreal.Pierre de Grand-pré, advocate, and Yolande Robichaud, secretary, botll of Saint Lambert, for the following purposes: To orgaidzc a catholic centre for guidance, meeting and educational purposes for persons desirous of being informed regarding family or matrimonial problems, under the name of \"L'Anneau-Centre d'Orientation des Foyers Canadiens Inc.\".with a total capital of 85,000, divided into 500 common shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at 373 Carré Saint Louis, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of October, 1950.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13151-50) Lanza Steak House Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of October, 1950, incorporating: Theobald Plamondon, Joseph Lanza, executives, both of Montreal, and Marcel Champagne, accountant, of Pointe-aux-Trembles, for the following purposes: To promote, establish, conduct, maintain a restaurant, a café, a grill, under the name of \"Lanza Steak House Ltd.\", with a total capital QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 2/,th, 1956, Vol.88, No.47 3807 840,000, divisé on 200 actions ordinaires «l'une valeur au pair de 8100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf octobre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729 P.FRENETTE.(P.G.12888-50) L'Ecole Progressive Inc.Avis est donne qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a élé accordé par le Lieutenant-gouverneur de lu province «le Québec «les lettres patentes, en date du quatre octobre 1050, constituant en corporation: Christophe Loiselle, surintendant, Mme Jeanne Normandin-Loiselle, «lirectrice, épouse séparée de biens dudit Christophe Loiselle, ct Mine Yvonne Normandin, veuve, ménagère, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Enseigner en anglais et.en français les matières commerciales, la culture physique et le chant et toutes matières se rapportant à l'enseignement élémentaire et secondaire en général, sous le nom de \"L'Ecole Progressive Inc.\", avec un capital total «le 810,000, divisé en 400 actions «le 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, «listriet judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le quatre octobre 1050.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(P.G.12943-50) Les Produits Métalliques Provinciaux Inc.Provincial Metal Products Inc.Avis f a construction and improvement company, and to deal in building materials, under the name of \"Lexington Investments Ltd.\".with a total capital stock of $40.000, divide«l into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listriet of Montreal.Date dat the office of the Attorney General, this twentv-seventh dav of September, 1950.P.FRENETTE, 43720-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13215-50) Liberty Investment Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issiunl by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the eleventh day of October, 1950, incorporating: Roland Lamarre.Ephraim Lebœuf, both Lawyers and Q.C., and Raymond Lebœuf, lawyer, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of bond dealers, underwriters, investment brokers and share brokers, under the name of \"Liberty Investment Inc.\".with a total capital stock of $50,000, divided into 50.000 shares of $1 each.The head ofHce of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of October, 1959.P.FRENETTE, 43720-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.13003-50) (A.G.13003-50) ^ L'Oeuvre des Terrains dé Jeux de Grand'Mère L'Oeuvre des Terrains de Jeux de Grand'Mère Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Qué'bce des lettres patentes, en date du vingt-huit septembre 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Hervé Matteau, curé et vicaire forain, Gilbert Larue, curé', Joseph Deschênes, agent vendeur, Robert Philibert, ferblantier, Armand l'ellerin, menuisier, Gaston Paulin, agent des postes, Philias Vincent et Jcan-Roch Vincent, garagistes, tous de Grand'Mère, pour les objets suivants: Réunir les enfants, jeunes gens, jeunes filles et adultes, dans un but de récréation et d'amusement, et s'occuper de leur formation en général, sous le nom de \"L'Oeuvre des Terrains «le Jeux de Grand'Mère\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est dê $100,000.Le siège social de la corporation sera à Grand' Mère, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté .du bureau du Procureur général, le vingt-huit septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(P.G.13100-50) I.onhicr Metal & Refining Works Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accortlé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre octobre 1950.constituant en corporation: Rémi Loubier, commerçant, Gabriel Lou-bier, étudiant, tous deux de Beaumont, et Paul Langevin, comptable, «le Thetford-Mines, pour les objets suivants: Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutcnant-Oovcrnor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of September.1950, to incorporate as a corporation without share capital: Hervé Matteau.parish priest and dean, Gilbert Larue, parish priest, Joseph Deschènes, sales agent, Robert Philibert, tinsmith, Armand Pellerin, joiner, Gaston Paulin, post-office agent, Philias Vincent and Jean-Roch Vincent, garage-keepers, all of Grand-Mère, for the following purposes, To gather children, youths, young girls and adults for recreational and amusement purposes and to see to their general formation, under the name of \"L'Oeuvre des Terrains de Jeux «le Grand'Mère\".The amount to which the value of the immoveable propertv which the corporation mav hold is to be limited, is $100,000.The head oflice of the corporation will be at Grand'Mère.judicial «listriet of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-eight dav of September, 1950.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13100-50) Loubicr Metal & Refining Works Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of thé Province of Quebec, bearing «late the fourth day of October, 1950, incorporât ing : Rémi Loubier, dealer, Gabriel Loubier, student, both of Beaumont, and Paul Langevin, accountant, of Thetford-Mines, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 24th, 1956, Vol.88, No.47 3869 Fabriquer, raffiner et exercer le commerce de toutes les autres opérations concernant les métaux de toutes sortes, leurs produits ct sous-produits, sous le nom de \"Loubier Metal & Refining Works Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 300 actions communes de 8100 chacune ct en 100 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Beau-mont, comté de Bellechasse, district judiciaire de Montmagny.Daté du bureau du Procureur général, le quatre octobre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-o P.FRENETTE.(P.G.13109-50) Maricville Furniture Manufacturing Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf octobre 1950, constituant en corporation: Raoul Marin, Charles-Edouard Larivière, tous deux industriels, et Raoul Marin, fils, commis, tous de Marievillc, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de meubles, nouveautés de toutes sortes, du bois et autres matériaux, sous le nom de \"Maricville Furniture Manufacturing Limited\", avec un capital total de S50,000, divisé en 1,000 actions communes de $25 chacune et en 100 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Maricville, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le neuf octobre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(P.G.12709-50) Mary Rose Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf août 1956, constituant en corporation: John Di Massino, surintendant, Richard Di Massino, pérposé aux ascenseurs et Pauline Friedman, secrétaire, tous de Montréal, pour les objects suivants: Exercer le commerce de constructeurs et celui de propriétés immobilières, sous le nom de \"Mary Hose Realties Inc.\".avec un capital total de 850,000,.divisé en 50 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 450 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Date du bureau du Procureur général, le vingt-neuf août 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729 P.FRENETTE.(P.G.12951-50) Matte Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq septembre 1950, constituant en '\u2022orporation: Nicolas Mateesco, avocat, Alexandre \u2022lipa, évaluateur et Monica Berzeanu Mateesco.professeur, épouse séparée de biens dudit Nicolas To manufacture, refine and carry on business in all other operations concerning metals of all kinds, their products and by-products, under the name of \"Loubier Metal & Refining Works Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 300 common shares of 8100 each and into 100 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Beaumont, county of Bellechasse, judicial district of Montmagny.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of October.1950.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13109-50) Maricville Furniture Manufacturing Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.Jetters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of October, 1950, incorporating: Raoul Marin, Charles Edouard Larivière, both industrialists, and Raoul Marin, son, clerk, all of Maricville, for the following purposes: To operate an industry and business dealing in furniture, novelties of all kinds, wood and materials, under the name of \"Marieville Furniture Manufacturing Limited\", with a total capital stock of S50.000, divided into 1,000 common shares of 825 each and into 100 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Marieville, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of October, 1950.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12709-50) Mary Rose Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of August, 1950.incorporating: John Di Massino, superintendent, Richard Di Massino, Elevator Operator, and Pauline Friedman, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders and deal in immovable property, under the name of \"Mary Rose Realties Inc.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 50 common shares of a par value of 8100 each and into 450 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth dav of August.1950.P.FRENETTE, 43729-q Acting Deputy Attorney General.(A.G.12951-50) Matte Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of September.1950, incorporating: Nicolas Mateesco, lawyer.Alexandre Jipa, estimator, and Monica Berzeanu Mateesco, professor, wife separate as to property of the said Nicolas Mateesco, 3870 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 24 novembre 1956, Tome 88, N° 47 Mateesco, suivant la Loi de Roumanie, tous de-Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, de.construction et d'amélioration, sous le nom de \"Matte Inc.\", avec un capital total de 810.000, divisé en 10 actions ordinaires de 8100 chacune et 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le vingt-cinq septembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729 P.FRENETTE.according to the law of Rouman ia, af Montrcolall, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Matte Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listriet of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth dav of September, 1950.P.FRENETTE, 43720-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.125S0-50) \"> Nadeau & Nadcau Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date «lu vingt-quatre septembre 1950, constituant en corporation: André Quesnel, avocat, Wilfrid Deschênes, notaire, et Pierrette Dufault, sténographe, fille majeure, tous «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de prêt curd'argent, sous le nom de \"Nadeau & Nadeau Inc.\", avec un capital total de $225.000, divisé en 1,099 actions communes de $100 chacune et en 1.250 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt-quatre septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729-0 P.FRENETTE.(A.G.12580-50) Nadcau & Nadcau Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters paient have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing dale the twenty-fourth day of September 1950, incorporating: André Quesnel, advocate, Wilfrid Deschênes, notary, and Pierrette Dufault.stenographer, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on generally the business of lending money, under the name of \"Nadcau & Nadeau Inc.\", with a total capital stock of $225,000, divided into 1.090 common shares of $100 each and 1,250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Date*! at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of September, 1950.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12753-50) Nettoyeurs Rco Cleaners Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du vingt-cinq septembre 1950.constituant en corporation: Isidore Genest, de Normandin, Jean Juteau, de Roberval, et Marc-André Doré.f $10 each, ami into 500 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 455 Sainte-Rose Blvd., Saintc-Rose, West, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of October, 1956.P.FRENETTE, 43729 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12955-56) Roma Land Sales Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of September, 1056.incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Theodore II.Polisuk.law student, and Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Roma Land Sales Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 10,000 common shares of SI each.The head office of the company will be at 201, Jean Talon St., East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of September, 1950.P.FRENETTE, 43729-o Acting'DeputyJAttorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 2/,th, 1966, Vol.88, No./,7 3875 (P.G.12973-5G) Ruth Fcit Inc.Avis est donné qu'en vertu f the company will be at Montreal, judicial «listriet of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of September.1959.P: FRENETTE, 43729-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12944-50) Scnneville Yacht Club Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-fourth day of September, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: II.Heward Stikeman, lawyer, of Westmount.James Bartlett Morgan, of Montreal, Whitham Taylor-Bailey, both executives and Frederick William R.Angus, engineer, both of Senneville, for the following purposes: To organize an«l carry on a club for yachting, sailing and related social and sporting activities, under the name of \"Senneville Yacht Club\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold its to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at 1455 Union Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fourth dav of September.1950.P.FRENETTE, 43729-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13071-50) Shubert-Diamond Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of October, 1950, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch.Abraham Sinister, advocates, and Max Shenker, law student, all four of Montreal, for the following purposes: To act as an investment corporation, under the name of \"Shubert-Diamond Investment Corporation\", with a total capital stock of $110,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $10 each and into 10,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of October, 1956.P.FRENETTE, 43729-0 Acting Deputy Attorney General. 3876 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 24 novembre 1956, Tome 88, N° 47 (V.C.13102-.%) Si.El/.car Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a çté accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois octobre 1950, constituant en corporation: Myer Chartorisky, Srull Mussman, Harry Steinberg, Moszek Wolf Zalcsztain, tous marchands, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'un immeuble situé dans la paroisse de St-Elzéar, comté de Laval, sous le nom de \"St.Elzéar Development Corp.\", avec un capital total de 810.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois octobre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729 P.FRENETTE.(P.G.13119-50) Strategic Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq octobre 1950, constituant en corporation: Henri Crépeau, Jean Miquelon, tous deux avocats ct CH., et Charles Edward Gibsôn, agent, tous de Montréal, pour les .objets suivants: Exercer le commerce comme entrepreneurs généraux, bûcherons, exploitants des forêts, marchands de bois et propriétaires de scieries, moulins à planer et à pulpe, sous le nom de \"Strategic Construction Co.Ltd.\", avec un capital total de 810,000.divisé en 10.000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq octobre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729 P.FRENETTE.(A.G.13102-50) St.Elzéar Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing dale the third day of October.1959.incorporating: Myer Chartorisky, Srul Mussman, Harry Steinberg, Moszek Wolf Zalcsztain, all merchants, of Montreal, for the following purposes: To deal with an immoveable situated in the parish of St.Elzear, county of Laval, under the name of \"St.Elzéar Development Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shards of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of October, 1956.P.FRENETTE, 43729-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13119-50) Strategic Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of October, 1950, incorporating: Henri Crépeau, Jean Miquelon, both Advocates and Q.C., and Charles Edward Gibson, agent, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors, loggers, lumbermen, lumber merchants and saw-mill, planing-mill and pulp-mill owners, under the name of \"Strategic Construction Co.Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 10,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.- Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of October, 1950.P.FRENETTE, 43720-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.13139-50) Suburban Telcserviee Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie do la Loi des compagnies de Québec* il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des Ici très patentes, en date du six octobre 1956, constituant en corporation: David M.Campbell, marchand, George Whelan, avocat, John DiMassino, surintendant, Toshiko Makatsuka, dactylo, fille majeure, tous de Montréal, et Hyman Eric Fcigelson.avocat, de la ville de Côte St-Luc, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à pourvoir des moyens de transmission, transport, translation, diffusion, enregistrement, reproduction et réception de signaux de télévision et de radio, sous le nom de \"Suburban Teleservice Inc.\", avec un capital total de $500,000, divisé en 112,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 387,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à West-mount, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six octobre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 43729 P.FRENETTE.(A.G.13139-50) Suburban Teleservice Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of October, 1950, incorporating: David M.Campbell, merchant, George Whelan.advocate, John Di Massino, superintendent, Toshiko Nakatsuka, typist, spinster of the full age of majority, all of Montreal, and Hyman Eric Feigelson, advocate, of the town of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on the business of providing means for the transmission, conveying, relaying, diffusion, recording, reproduction and reception of television and radio signals, under the name of \"Suburban Teleservice Inc.\", with a total capital stock of $500,000, divided into 112,500 common shares of a par value of $1 each and into 387,500 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Westmount, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of October, 1956.P.FRENETTE, 43729-0 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November BAth, I960, Vol.88, No.A7 3877 (P.G.12996-5G) Ta I frank Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec.il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec îles lettres patentes, en date du vingt-sept septembre 1956.constituant en corporation: John Maria Cerini, C.R., Gilles Duchesne, tous deux de Montréal et Herbert Clements Salmon, de West mould, tons avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce d'une compagnie de terrains, construction et améliorations\" et celui de matériaux de construction, sous le nom de \"Tall'rank Corporation\", avec un capital total de 85,000, divisé en 500 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1565 rue Cabot, Montréal, «listriet judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt-sept septembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.13729 P.FRENETTE.(P.G.13216-56) The Hoover Mining & Exploration (Quebec) Company Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en «late du onze octobre 1956.constituant en corporation: R«>land Lamarre, Ephraim Lebœuf.tous deux avocats et C.R., et Raymond Lebœuf, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire «les recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"The Hoover Mining & Exploration (Quebec) Company Limited\" (No Personal Liability), avec un capital total de 85.000,000, divisé en 5,000,000 .factions de 81 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal.ergpr, 1050, Dorcliestcr ouest West, appt.-Apt.508, Montréal, P.Q.M.-Mr.l'Iorian Lapréc.prom.-acquéreur-prom.buyer.195)6, Bédard, It.H.N° 5, Bouclierville.P.O.M.-Mr.O.T.Davis, Box 301, Rancho Tctela.Cucrnavaca, Morelos, Mexico.M.-Mr.O.T.Davis, Box 301, Rancho Tetola.Cuernavaca, Morelos, Mexico.Dame Goyer Poulin, prom.-acquéreur-prom.buyer, 2409, Bédard.It.R.N° 5 Bouclierville.P.Q.M.-Mr.Marcel Therreault.8788.Roui.St-Michel.Ville St-Michel.P.Q.M.-Mr.Lonier Poirier, prom.-acquéreur - prom.buyer.2451 Bédard, R.R.N° 5, Bouclierville.P.Q.M.-Mr.O.T.Davis.Box 301.Rancho Tetela.Cucrnavaca, Morelos, Mexico.M.-Mr.O.T.Davis.Box 301; Rancho Tctela.Cucrnavacn, Morelos, Mexico.Mile-Miss Alma Banner, 1273, St-Jacqucs, Jacques-Cartier.P.Q.M.-Mr.R.Vcndctte, Prom.-acquércur-prom.-buy- er, 2225, Lincourt, Jueques-Cartier.P.Q.M.-Mr.O.T.Davis.Box 301.Rancho Tctela.Cuernavaca, Morelos, Mexico._ M.-Mr.Michel Adolphe Sauriol.2281,Ch.Cham- bly-Rd.Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Arthur Patry, 1854, Bédard.R.R.N° 5.Bouclierville, P.Q.M.-^Mr.O.T.Davis, Box 301, Rancho Tetela.Cuernavaca, Morelos, Mexico.M.-Mr.Jean Boucher, prom.-acquéreur, - prom.buyer, 2075, Lebrun, Jacques-Cartier, P.Q.Mllo-Miss Marielle Moquin (faillie-bankrupt) Gérard Biais, es qualité syndic \u2014 in the capacity of Trustee, 1833\", Sherbrooke est-East, Montréal p.é.M.-Mr.Marcel Thcrrault.8788, Boul.St.Michel.Ville St-Miehel, P.Q.M.-Mr.Bon Lochter, 1410, Peel.Montréal, P.Q des lots 50-419, 420 et 421, en arrière par partie du lot 50-418 ct de l'autre côté par le lot 56-422.\u2014 measuring 84 foet in width by 90 feet in depth, all of which in English measure and more or less, bounded in front by Bédard Street, on one side by the residue of lots 56-419, 420 and 421, in the rear by part of lot 56-418 and on the other side by lot 56-422.56-369 50-7S.79 56-140, 141 56-148.149 56-65.66 56-74.77 56-603.662 56-656.657 56-30.31 56-P.419.P.420.P.421 \u2014 Ces parties de lots mesurant 24 pieds de largeur par !>0 pieds de profondeur, bornées en front par la rue Bédard, d'un côté par le résidu des dits lots, en arrière par partie du lot 50-418, ct de l'autre côté par le lot numéro 56-422.Toutes les mesures sont anglaises et plus ou moins.\u2014 These parts of lots measuring 24 feet in width by.90 feet in depth, bounded in front by Bédard Street, on one side by the residue of said lots, in the rc.-ir by part of lot 56-418, and on the other side by lot number 56-422.All in English measures and more or less.56-302.303 56-305.à 307 54-13 54-7 54-6 54-5 54-4 P.108 \u2014 Un lopin do terre situé en la cité de Jacques-Cartier, autrefois la paroisse de St-Antoine de Longueuil, mesurant cent quatre-vingts pieds de largeur jusqu'à une profondeur do sept arpents, et de là une largeur de cent quatre-vingt-douze pieds jusqu'à une profondeur de onze arpents, ayant en tout le dit lopin do terre dix-huit arpents do profondeur, connu ct désigné comme faisant partie du lot numéro cent huit (N° 108) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Antoine do Longueuil, dans le comté de Chambly et borné, ledit lopin de tone, comme suit, savon : En front par le Chemin de Chambly tel qu'actuellement élargi, d'un côté par le lot numéro 107.des susdits plan et livre de renvoi officiels appartenant à Joseph Rt Goyette, de l'autre côté et en arrière par le résidu dudit lot numéro 108; A distraire cependant: \u2014 Cette partie vendue par ledit Lorenzo Martel à Herbert Thomas, par et aux ternies d'un cate de vente enregistré sous le numéro 102807.\u2014 A plot of land situated in the city of Jacques Cartier, formerly the parish of St.Antoine de Longueuil, measuring one hundred and eighty feet in width as far as a depth of seven arpents, and thence a width of one hundred and ninety-two feet as far as a depth of eleven arpents, having QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 201, 1956, Vol.88, No.A7 3901 Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immoveable Major Holdings Ltd.Adresse inconnue \u2014 Address unknown M.Mr.O.T.Davis, Box 301, Rancho Tetela Cuernavaca, Morelos, Mexico M.Mr.Armand Nantais, 1573, Notre-Dame de Grâces.Jacques-Cartier, P.Q.M.Mr.Oscar Soulière, Adresse inconnue - Address unknown.M.Mr.Ezéar Labrie, 861, Victoria, Jacques-Cartier, P.Q.Dame Irène Provencher, Vve-Widow Ovide Frechette.Adresse inconnue-Address unknown M.-Mr.Adrien St-Martin.prom.-acquéreUr\u2014 prom.buyer, 883 Victoria, Jacques-Cartier.P.Q M.-Mr.Fabien Santoire, 1241, Victoria, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Lionel Massé, 892, Victoria, Jacques-Cartier.P.Q.M.-Mr.Roger Chartiée, 1664, Victoria, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Arthur Brodeur, Adresse inconnue - Address unknown M.-Mr.Henri Bertrand.947, Gardenville.Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Agnus Rondeau, 1012, Gardenville, Jacques-Cartier.P.Q.M.Paul-Emile H6tu, 1020, Gardenville.Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Germain Hétu, 1036, Gardenville, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Georges Ethier, 1079, Emma, Jacques-Cartier.P.Q.M.-Mr.Edoua.d Lagacé, 1099.Joliette, Jacques-Cartier.P.Q.M.-Mr.Raoul Gingras, 1582, Joliette.Jacques-Cartier.P.Q.M.-Mr.Hormidas Lamer, 1712 Joliette, Jacques-Cartier.P.Q.M.-Mr.Guv-F.Dubuc.1300 Blvd Rainville.Montréal-Sud-Routh.P.Q.Dame Roméo Martineau.prom.-acquéreure \u2014 prom.buyer, 6040, 5ième-th.Avenue Rosemont.Montréal.M.-Mr.Nicholas Garito, 1643.Marnier, Jacques-Cartier.P.Q.4 M.-Mr.Herbert Montgomery, Laval Ouest-West P.Q.M.-Mr.Rocer Dubuc, 1095 Dorion, Jacques-Cartier, P.Q.Au rôle \u2014On roll: M.-Mr.Arthur Gendron, 1651 Westgate.Jacques-Cartier.P.Q.M.-Mr.Guv.-F.Dubuc, 1300 Blvd Rainville.Montréal-Sud-South.P.Q.Dame Henri DeFranscise.prom.-acquéreure, \u2014 prom buyer 3919.Berri.Montréal.P.Q.M.-Mrs Raoul Pinard, 1092, Westgate.Jacques-Cartier.P.Q.M .-Mrs Antonio Lemay, 1126, Westgate, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Léo Aubin, 5>£ rue Mance, Street Hull, PQ.M.-Mr.Philippe Baillargcon, 1660 Dollard, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Antonio Cardinal, 749, Hindland, Jaeques-.Cartier.P.Q.M.-Mr.Joseph Charbonneau, 1657, Hindland, Jacques-Cartier, P.Q.Au rôle-On roll: M.-Mr.Wilfrid Charbonneau.M.-Mr.Maurice Sarazin, 1697.Hindland, Jacques-Cartier.P.Q.y in all, the said plot of land, eighteen arpents in depth, known and designated as forming part of lot number one hundred and eight (N° 108) of the official plan and book of reference of the parish of St.Antoine de Longueuil, in the county of Chambly and bounded, the said plot of land, as follows, to wit: \u2014 In front by the Chambly Road in its present width, on one side by lot number 107, of the aforesaid official plan and book of reference belonging to Joseph R.Goyctte, on the other side and in the rear by the residue of said lot number 108; Save however: \u2014 That part sold by the said Lorenzo Martel to Herbert Thomas, by and according to the terms of deed of sale registered under number 102867.Ill \u2014 A distraire la partie vendue par Félix Emard au Ministère do la Voirie de Québec pour l'élargissement du Chemin do Chambly, appert acte enregistré sous N° 76369.\u2014 111 \u2014 Save and except that Quebec part sold by Félix Emard to the Department of Roads for the widening of the Chambly Road, according to a Deed registered under number 76369.307-49 138-475.476 138-449.450 138-39, 40 \u2022 138-45, 46 138-306.307 138-99, 100 138-373, 374 140-37, 38 140-63 140-1S9, 190 140-191 140-194, 195 140-224.225 140-270.271 140-501, 502 140-669, 670, 671 140-675 / 140-676.677 140-716, 717 140-741 à-to 743 141-255 à-to 257 141-40, 41 141-42, 43 * 141-49, 50, 51 141-163, 164 141-362, 361 142-292 141-389 141-396 3902 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.24 novembre 1966, Tome 88, N° 47 Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immoveable M.-Mr.Wilfrid Brammall, adresse inconnue-Addresa unknown.M.-Mr.Guy F.Dubuc, 1300 Blvd Rainville, Montréal.Sud, P.Q.\u2014 Damo J.Alario Caya.prom.-acq.-prom.buyer 1136, Hindland.Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Marcel Rochclcau, adresse inconnuo.-Address unknown.\u2014 M.-Mr.Charbonneau, prom.-acq.-prom.buyer, 1671, Hindland, Jacques-Cartior, P.Q.M.-Mr.Joseph Rayle.420.St-Thomns.Lon-guouil, P.Q.\u2014 Damo Alice Dufour-Hétu, prom.-acq.-prom.buyer.723, Marquette, Jncques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Roméo Tremblay, 33, rue Windsor Street ' Sto-Rose, comté do Laval, P.Q.M.-Mr.Lucien Bisonnette, 1105 Marquette, Jacques-Cartior, P.Q.M.-Mr.Roger Dubuc, 1095 Dorion, Jacques-Cartier.P.Q.M.-Mr.Lucien Desrosiers, 1190, Dorion, Montréal.P.Q.M.-Mr.Armand Lavoie, 1174, Marquette.Jacques-Cartier.P.Q.M.-Mr.J.Adalbert Daignoault, 1542, Marquette, Jacques-Cartior, P.Q.MM.-Messrs Joan Simard et-and André Simard, adrosse inconnuo.-Address unknown.141-397 142-236 \u2014 A distraire parties vendues apport actes enregistrés sous les numéros 10670!), 109162.110600.110699, 134237.\u2014 142-230 Save and except parts sold according to deeds registered under numbers 100709, 109162.110066, 110699, 134237.P.141 \u2014 mesurant 100 pieds de largeur à la profondeur vers le sud-ouest.38 pieds do profondeur du côté sud-est et 48'8\" do profondeur du côté nord-ouest, mesure anglaise Borné en front par la rue Hindland, eu arrièro par les lots nos.310-50, 51 et 52, des doux côtés par partie dudit lot 141.\u2014 P.141 \u2014 measuring 100 feet in width at its depth to the southwest 38 feet in depth on the southeast side and 48'8\" in depth on the northwest side, English measure.Bounded in front by Hindland Street, in the rear by lots No.310-50, 51 and 52.on both sides by part of said lot 141.142-225 142-208 ct 142 P.209 \u2014 mesurant 4 pieds do largeur par 130.8 pieds de profondeur, borné en front par la rue Marquette, en arrière par la ligne arrière dadit lot,\u2014 d'un côté par le lot 142-208 et do l'autre côté, par le résidu dudit lot 142-209 \u2014 142-208 and 142 P.209 \u2014 measuring 4 feet in width by 130.8 feet in depth, bounded in front by Marquette Street, in the rear by the rear lino of said lot \u2014 on one sido - by lot 142-208 and on the other side bv said lot 316-7.8 (142-209.316-9 142-P.119 \u2014 mesurant 47 pieds de largeur par 100 pieds do profondeur mesure anglaise.Borné en front par la rue Marquette, en arrière par partie du lot 142-118, d'un côté par 142-110 .et de l'autre côté par le résidu du lot 142-119.\u2014 142-P.119 \u2014 measuring 47 feet in width by 100 feet in depth.English measure.Bounded in front by Marquette Street, in the rear by part of lot 142-118.on one side by 142-116 and on the other side by the residue of lot 142-11'.).142-82.83 142-308, 309 142-H de 88.\u2014 Paroisse de St-Antoine do Longueuil, mesurant 25' de largeur sur 100' do profondeur, mesure anglaise plus ou moins et bornée comme suit: au sud-ouest par le lot numéro 142-85; d'un côté par le lot no.142-81) et de l'autre côté par le résidu ou l'autre moitié dudit lot No.142-88 dudit cadastre.\u2014142-H of 88.\u2014 Parish of St.Antoine de Longueuil, measuring 25' in width by 100' in depth, English measure, more or less and bounded as follows: southwesterly by lot number 142-85; on one side by lot No.142-89 and on the other side by tho residue or other half of said lot No.142-88 of said Cadastre.Lot N° 142- unknown.M.-Mr.Bernett Rudokoff, adresse inconnue-address unknown.Trenton Park Ass.adresse inconnue-addres?unknown.M.-Mr.Michel Adolphe Sauriol.2281 Chemin Chambly, Jacques-Cartier, P.Q.Dame Eléonorc Godin, veuve do-widow of Eugène Dubreuil, adresse inconnue-address unknown M.-Mr.Roger Lacerte.0971.Iberville, Montréal Dame Maria Mastrocola, veuve de-widow of Giovanni Raraacieri, 3909, Berri, Montréal, P.Q.Dame J.VV.II.Short, adresse inconnue-addres.-unknown.Dame Anna Maria Jack, épouse de-wife of George Wilson.Briar Hill, Street, Crystal Falls, Mich.U.S.A.M.-Mr.Georges Poirier, 1193, Victoria, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Marcel Pellerin & son épousc-his wife Gertrude Hoff, 1140, Victoria, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Marcel Pellerin, 1146, Victoria, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Marcel Richard, 1636, Sanguinet, Montréal, P.Q.M.-Mr.William T.Tucker, 22 Bcllwood, Ottawa, Ont.M.-Mr.William T.Tucker, 22 Bellwood, Ottawa, Ont.M.-Mr.Guy.-F.Dubuc, 1300, Blvd Rainville, Montréal-Sud-South, P.Q.56-250 ù-to 252.1.\u2014 P.54 \u2014 mesurant 2 arpents de largeur par 24 arpents de profondeur, borné en front par Chemin du Lac.en arrière par partie dudit lot, d'un côté par le lot 55 et de l'autre côté par partie du lot 54; 2.-P.54 \u2014 mesurant 2 arpents de largeur par 4 arpents de profondeur, borné au nord-ouest par la partie du lot 64 ci-dessus décrite, au sud-est par les lots 54-1, 25 et 26 et partie 54.d'un côté, au sud-ouest par le lot 55 et de l'autre côté au, nord-ouest par partie 54.\u2014 l.-P.54 \u2014 measuring 2 arpents in width by 24 arpents in depth, bounded in front by tho Lake Road, in rear, by part of the said lot, on one side, by lot 55 and on the other side by part of lot 54; 2.-P.54 \u2014 measuring 2 arpents in width by 4 arpents in depth, bounded on tho northwest by that part of lot 54 hereinabove described, on the southeast, by lots 54-1.25 and 20 and part of 54.on one side, on the southwesterly lot 55 and on the other side, on tho northwest by part of 54.56-451.56-138, 437, 439.56-434.56-433.56-372.56-239.56-463, 466.56-508.56-511.56-84, 87.56-88, 91.56-464, 465.56-6S7, 686.56-11, 10.56-5, 4, 3, 2, 1.56-507.50-506.56-505.56-502.56-503, 504.44-294 à-to 297, 44-85 à-to 83.138-30 138-416.417.138-101, 102.138-191, 192.138-196, 197, 198.138-203, 264.138-265, H 266.139-09.139-26.140-458, 459.140-400, 401.140, 625, 626. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November ÎLth, 1956, Vol.88, No.47 3915 Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immoveable Dame Catherine Hurley, vve de-widow of Patrick Carey, 351, Slater Ave.Ottawa, Ont.M.-Mr.George H.Caroll, adresse inconnue-adress unknown.Mrs.Arthur John Jackson, 10, St-Charles, Ayl-mer.Ont.Mrs.Arthur John Jackson, 10, St-Charles, Ayl-mer, Ont.Mrs.Arthur John Jackson, 10, St-Charles, Ayl-mer, Ont.M.-Mr.James McEwcn Davidson, P.O.43, Pointe Gatineau, P.Q.Mr.James S.Bayes, 172, Oxford Street, Halifax, N.S.M.-Mr.Zenon Dussault, 1481, Ste-Roso, Montréal, P.Q.M.-Mr.Guy-F.Dubuc, 1300 Blvd Rainville, Montréal-Sud.P.Q.M.-Mr.Gérard Lefort, 1879, Delorimier, Montréal.P.Q.M.-Mr.Gérard Lafond, 2091, St-André, Montréal, IS/lM't.Guy.F.Dubuc, 1300, Blvd Rainville Montréal-Sud-South.P.Q.M.-Mr.Guy.-F.Dubuc, 1300, Blvd Rainville Montréal-Sud-South, P.Q.M.-Mr.Roland Tourangeau.Marcel Tourangeau et and Dolores Tourangeau, 1770, Marquette, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Georges Bisaillon, 993, St-Georges, Jacques-Curtier, P.Q.M.-Mr.Joseph Berthiaume, adresse inconnue-address unknown.M.-Mr.Joseph-Eugène Beaudry, 903, Blvd Taschereau, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Albert MacKay, 1320, ouest St-Jacques, West.Montréal, P.Q.M.-Mr.Liguori Gagnon, 837, Guilford, Montréal, P.O.M.-Mr.Albert St-Pierre, 1250, Green, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Allan Wiltshire, 1546, Guy.Montréal, P.Q.M.-Mr.Jean-Louis Robert, 114, Robertson, Granby.P.Q.Dame Lydia Vipond.épouse de-wife of Hallace, Hilson; Dame Dorothea Vipond, épouse de-wife of Hanson Kemp; Dame Hortense Vipond, épouse de-wife of Thomas S.Moore; Dame Irène Vipond, épouse de-wife of Howard Kemp; Dame Jean Vipond, épouse de-wife of Albert Shouldice, Hilbert Vipond.M.-Mr.Camille Martin, adresse inconnue-address unknown.M.-Mr.Guy F.Dubuc, 1300 Blvd Rainville, Montréal-Sud-South.P.Q.Dame Béatrice Charron, épouse de-wife of Emery Charron, 853, Cartier, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Guy.-F.Dubuc; 1300 Blvd Rainville, Montréa-Sud-South, P.Q.M.-Mr.Louis-Philippe Patenaudo, 1530, Lasalle, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Donat Bemeur, 1689, Marinier, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Joseph Deneault, adresse inconnue-address unknown.M.-Mr.Jean-Jacques Lavoie, adresse inconnue-address unknown.M.-Mr.Cyrillo Allie, adresse inconnue-address unknown.Dame Emma Tousignant, 735, Blvd Taschereau, Jacques-Cartier, P.Q.United Loan Corp., 1290.St-Denis.Montréal, P.Q.M.-Mr.Robert Poitras, 11,407, Blvd Gouin Est.Montréal.P.Q.M.-Mr.Henri) Champagne, 1810, Patricia, Ville St-Laurent.P.Q.M.-Mr.Henri Champagne, 15, Patricia, Ville St-Laurent, P.Q.Suc-est.C.E.Manseau.735, Blvd Taschereau, Jacques-Cartier, P.Q.Succ.-est.C.E.Manseau, 735, Blvd Taschereau, Jacques-Cnrtier, P.Q.M.-Mr.Alfred Couture, 359, Rouvillt, Jacques- Cartier, P.Q.140, 318, 319 140, 721 140-746, 747, 141-261 140, 748, 749, 141-262, 263 140, 750 à-to 752 141-264 à-to 266 141-64, 65 141-381, 382, 383 142-224 - 142-165 142-132 142-124 142-47 142-41 \u2014 à distraire partie vendue par acte enregistré sous no.103434.\u2014 142-41 \u2014 to withdraw part sold by registered deed Under No.103434.143-520, 521 143-312 143-298, 299 143-377 145-34 145-130 146-.699, .700 \u2014 à distraire parties vendues par acte enregistré sous no.131534.\u2014 146-.699, .700 \u2014 to withdraw parts sold by registered deed under no.131, 534.146-802, 803 147-449, 450 140-147, 148 140-149, 150 140-151, 152, 153 141-32, 33 141-38 112-.220 \u2014 à distraire partie vendue par acte enregistré sous no.123421.\u2014 142-.220 \u2014 to withdraw part sold by registered deed under No.123421 142-192.191, 190 140-753.754 140-647, 648 141-348 142-441, 442 142-443, 444 116-824, 825, 826 160-440.441 160-424, 425 160-284 159-930 147.30, 31 160-2.7, 160-2, 8 147-33 160-2-11 159-704 391G GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2£ novembre 1956, Tome 88, N° 17 Folio Nom ct adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immoveable 3/2-4958 4-6 4-669 4-699 4-707 4-748 4-856 4-881 4-963 4-1010 4-1037 4-1057 4-1059 4-1062 4-1065 4-1150 4-1155 4-1161 4-1202 4-1219 4-1275 4-1310 4-1381 4-1463 4-1683 (x) 4-1471 4-1598 4-1724 4-1890 4-1896 4-1916 4-1918 M.-Mr.Marcel Godon, 342, Duluth, Montréal P.Q.M.-Mr.Edouard Villeneuve, 1775, Notre Dame de Graces, Jacques-Cartior, P.Q.Benjamin Adolphe Whartin et-and Mlle-Miss Edna Wharton, 721, Versailles, Montréal, P.Q.M.-Mr.Jean-Paul Dubuc, 975, Hindland, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Guy.-F.Dubuc.1300, Blvd Rainville, Montréal-Sud-South.P.Q.Dame Eléonard Lévesque, épouse dc-wife of Henri Dumais, 2086, Cartier, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Guy F.Dubuc.1300, Blvd Rainville, Montréal-Sud-South, P.Q.M.-Mr.Roger Dubuc, 1095, Dorion, Jacques-Cartier, P.Q.Dame Germaine Lamarre, épouse de-wife of René Ménard, adresse inconnue-address unknown.Au rôle-on roll: M.-Mr.Jean-Paul Dubuc, 975, Hindland, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.John Jaroslowski, 5150 Bourbonnière, appt-apt.3, Montréal, P.Q.M.-Mr.Raymond Fccteau, 870, Curé-Poirier, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Léo Kolber.132.St-Jacques, Ouest \u2014 St.Jame3 West, Montréal, P.Q.M.-Mr.Guy-F.Dubuc.1300, Blvd Rainville', Montréal-Sud-South, P.Q.M.-Mr.Michel Nassif, 1005, Côteau-Rouge, Jacques-Cartier, P.Q.Paroisso-Parish St-Antoino de Longueuil Au rôle-on roll: Guy F.Dubuc, 1300 Blvd Rainville Montréal-Sud-South, P.Q.M.-Mr.Michel Nassif, 1005 Coteau-Rouge, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Guv-F.Dubuc, 1300, Blvd Rainville, Montréal-Sud-South, P.Q.M.-Mr.René Ménard, 1154, Ste-Hélène, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Pierre Céré et M.Paul Charlebois, 640, 6ième-th Avenue, Rosemont, Mtl.P.Q.M.-Mr.Roger Dubuc, 1095, Dorion, Jacques-Cartier, P.Q.Dame Germaine Lamarre, ép.-wife René Ménard, 1154, Ste-Hélène, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Sarto Dubuc, 1158, Harrison, Montréal-Sud-South, P.Q.M.-Mr.J.B.Goulet, Adresse inconnue-Address unknown.Dame Mériza Roy, ép.-wife, Donat Labonté, 2153, Marquette, Jacques-Cartier, P.Q.Dame Emelia Lauzicr, ép.-wife, Alphonse Dufort, 781, Cartier, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Emile Bordeleau et son épouse Philomène Norbert, 1916, Marquette, Jacques-Cartior, P.Q.M.-Mr.Rupert Belgrave, 1890, Lincoln, Apt 4, Montréal, P.Q.M.-Mr.Léonard Brown, 6630, 15ièmo Avenue, Rosemont, Mtl.P.Q.Dame Emma Tousignant vve en premières noces de C.E.Manseau et l'épouse en secondes avec Lionel J.Turcotte.Au rôle-on roll: M.G.Danseroau-G.Allard 9885, St-Dehis, Montréal, P.Q.Dame Emma Tousignant, vve en première noces do C.E.Manseau, et l'épouse en secondes avec 100-309, 310 138-590, 591, 592 140-1101, 1102 14-1244, 1245 140-1252, 1253 140.970, 977 \u2014A distraire du lot 140-976 la partie venduo à la Voirie appert à acte enregistré sous le numéro 131760.\u2014 140, 970, 977 \u2014 To withdraw from lot 140-976 that part sold to tho Roads Dept.appears on registered deed number 131760.140-1007 140-1171, 1172 140-1052, 1053 140-1356 141-125, 426, 140-907, 908 140-1068, 141-587 141-589, 590, 591, 140-1070, 1071, 1072 141-592, 140-1073 141-595.140-1076 141-474, 475 141-479 141-618, 619 141-791 141-888 141-654 141-909, 910 141-088 141-694, 095 141-096 \u2014 A distraire partie venduo à la Voirie, le tout appert à acte enregistré sous le numéro 133931.\u2014To withdraw part sold to Roads Dept, the whole appears in deed registered under number 133931.141-702, 703 P.316 \u2014 mesurant 00 pieds de largeur par 66 pieds do profondeur, mesure anglaise bornée en front par la ruo Marquette, en arrière par la ligne arrière dudit lot, des deux côtés par parties du 316.\u2014 measuring 60 feet in width by 66 feet in depth, English measure, bounded in front by Marquette Street, in rear by the rear line of the said lot, the two sides by parts of 316.Jïcdit emplacement est JJdo forme rectangulaire, et sa ligne nord-ouest est parallèle à la bordure sud-est de la quatrième avenue ou le Boulevard Nobcrt, se trouve à deux cent quarante pieds (240') de la susdite bordure de la rue précitée.This said emplacement is of rectangular form and its northwest lino is parallel to the southeast border of fourth avenue, or Nobert Bou c-vard, is to be found two hundred and forty feet (240') from tho above said border of the above cited street.142-558 142r585.586 142-591.592 142-689, 690 142-091, 092 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 2J,th, 1956, Vol.88, No.17 3917 Nom ot adrcsso Name and address Description do l'immeuble Description of immoveable Lionel J.Turcotte.\u2014 Damo Emma Tousignant.widow by first marriage of C.E.Manseau, and wife by second marriage with Lionel J.Turcotte.Au rôlo \u2014 On roll: M.E.Jonnnctte-G.Gravel, 4244, Coloniale.Montréal, P.Q.M.-Mr.Gérard Danscrcau, 2424, Cartier, Jacques-Cartior, P.Q.M.-Mr.Albert Labclle, 192G, Préfontainc, Jacques-Cartior, P.Q.M.-Mr.Lucien Labelle, Ch.Chambly, ltd.St-IIu-bert.P.Q.M.A.Allvn.2077, Duqucsnc.Montréal.P.Q.M.-Mr.Allen WoodrofTe, 1192.St-Antoine, Montréal.M.-Mr.Emile Ncpvcu, 2074, St-Alexandre, Montréal, P.Q.M.-Mr.Calixte Courtemancho, 4207, Boyor, Montréal, P.Q.M.-Mr.Georges Guénctte, 10947, Bellerive, Mont-réal-Nord-North.P.Q.M.-Mr.Valentino Crikietis, 0303, Jogues, Montréal.P.Q.M.-Mr.Paul Dufault, 870, Ste-Hélène, Montréal-Sud-South, P.Q.Dame Emma Tousignant, vvo en première noces de C.E.Manseau et l'épouse en secondes noces de Lionel Turcotte.\u2014 Dame Emma Tousignant, widow by first marriago of C.E.Manseau and wife by second marriage of Lionel Turcotte.Municipalité Scolaire Catholique do la paroisse\u2014 Parish of Longueuil Au rôlc-On roll: M.-Mr.Léo Sénécal, 100 Ste-Margucrite.Mtl.P.Q.M.-Mr.Ubald Paiement.Adresse inconnue.\u2014 Address unknown.John W.Campbell, 2212, Papineau, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.John Lavergne, Adresse inconnue.\u2014 Address unknown Au rôle\u2014On roll: Dame F.Dovino & Dame W.G.Williams.621 N.Damo Gatineau Mills.P.Q.M.-Mr.Marcel Deaudelin, 1172, Beauregard, Jacques-Cartier, P.Q.Dame Emma Tousignant, vve en première noces de C.E.Manseau et l'épouse en secondes noces de Lionel J.Turcotte.\u2014 Dame Emma Tousignant widow by first marriago of C.E.Manseau and wife by second marriage of Lionel J.Turcotte.Au rôle \u2014On roll: M.-Mr.Lionel Dallaire, 1461, Logna, Montréal, P.Q.M.-Mr.John C.Czyz, 2465, Centre, Montréal, 142-930, 910, 143-1312, 1313 142-1028, 1029, 143-1424, 1425 1 12-1030, 1033, 143-1426 à 1429 142-1146, 1147, 143-1549, 1550.143-1330 à-to 1339 143-1597, 1598, 1599 143-988.989 144-921, 922, 923 144-90-1, 965 144-967 144-592, 593 145-592, 593 144-592, 593 145-592, 593 145-330 Le lot numéro quatre cent cinquanto-sopt et la moitié sud-est du lot numéro quatre cont cinquante-six de la subdivision officielle du lot numéro originaire cent quarante-cinq (145-457 ct ^ sud-est 456) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisso de St-Antoine do Longueuil, mesurant ladite p.s.e.du lot N° 456, douze pieds et six pouces do largeur par cent six pieds et six pouces de profondeur, mesure anglaise, ct bornée en front, par la rue Delorimier, en profondeur par la ligne arrière dudit lot, d'un côté par le lot N° 145-457 et do l'autre côté par le résidu du lot N° 145-456.A distraire cependant dudit lot N° 145-457; Co morceau de terro mesurant six pieds et demi de largeur par toutes les profondeurs dudit lot, mesuro anglaise ct bornée comme suit, savoir: En front, par la rue Delorimier, en arrière par la ligne arrière dudit lot, d'un côté par le lot N° 145-458 et do l'autre côté par le résidu dudit lot N° 145-457.\u2014 Lot number four hundred fifty-seven and the southeast-half of lot number four hundred and fifty-six of the official subdivision of original lot one hundred and forty-five (145-457 and H southeast 456) on the official plan and in the book of reference of the parish of St-Antoine de Longueuil, measuring the said S.E.Pt.of lot No.456, twelve, foot and six inches in width by six feet and six inches in depth, english measure, and bounded in front, by Delorimier Street, in depth, by the rear line of the said lot, on one side by lot No.145-457 and on the other side by tho residue of lot No.145-456.To withdraw however from the said lot No.145-457; This plot of land measuring six feet and one-half in width by all the depths of the said lot, English measuro and bounded as follows, to wit: In front, by Delorimier Street in rear by tho roar lino of the said lot, on one sido by lot No.145-458 and on tho other side by tho residue of the said lot No.145-457.145-372, 373 145-651 à-to 654 145^655, 656 145-811 à-to 814 3918 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 24 novembre 1956, Tome 88, N* 47 Nom et adresse Name and address Description do l'immeuble Description of immoveable F.S.Mackay, Adresse inconnue \u2014 Address unknown Joseph Léodas Maher; Dame Malvina Sancho, vve de feu Damase Maher, widow of the lato Dama-60 Maher, Mlle\u2014Miss Généreuse Maher.Au rôle-on roll: M.-Mr.P.E.Maher & Mlle-Miss G.Maher.2279 Champlain.Montréal.Joseph Léodas Maher; Dame Malvina Sanche, vve de feu-widow of the late Damase Maher, Mlle-Miss Généreuso Maher.Mackay Relaty Incorporated & René Laporte es qualité de Syndic.-in lus quality of Trustee.Pierre Elzéar Maher Dame Malvina Sanche, vve-widow Damase Maher et-and Mlle-Miss Généreuse Maher.Au rôle-on the roll: voir-see page 14.M.-Mr.Daniel Lafortune, Pointe Gatineau, Co Hull.P.Q.M.-Mr Dmytro Atanam, 0734 DesEcores, Montréal Dame Annie Davis, vve-widow Joseph Norris, 7G6, Versailles, Montréal, P.Q.M.-Mr.Auréléan Téodorovici, adresso inconnuc-Au rôle-on roll: M.Clément Téodorooivi, 2222.Auger, Montréal, P.Q.M.-Mr.Auréléan Téodorovici, adresse inconnue-Au rôle-on roll: M.-Mr.Clément Téodorovici, 2222, Auger.Mtl.P.Q.M.-Mr.John Ewen Phillipps et son épouse-and his wife, Pearl Ida Durham, 2199, Bourbonnière, Montréal, P.Q.M.-Mr.Léo Kolber, 132, St-Jacques, O.-W., Montréal, P.Q.Benjamin J.Carr, adresse inconnuo-address unknown.Au rôle-on roll: Léo Kolber.132.St-Jacques, O.-W.Montréal.P.Q.M.-Mr.Jean-Marie Mantha Inc.2163, Blvd Taschereau, Jacques-Cartier, P.Q.St-Lambert Realty Co.Ltd.adresse inconnue-address unknown.Dame Hélène Parent, vve-widow Elie Dubuc, 1158, Harrison, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Guy-F.Dubuc, 1300.Blvd Rainville, Montréal-Sud-South.P.Q.M.-Mr.Guy-F.Dubuc.1300, Blvd Rainville, Montréal-Sud-South.P.Q.M.-Mr.Léo Kolber.132.St-Jacques-Ouest-St.James-West, Montréal.P.Q.St-Lambert Realty Co.Ltd., adresso inconnue-Address unknown.M.-Mr.Léo Kolber, 132.St-Jacques Ouest-St.James St.West.Montréal.P.Q.Mlle-Miss Katharine McKian, 238, Wilbrod, Ottawa.Ont.M.-Mr.Philias Choquette, 1717, Dufresnc, Montréal.P.O.M.-Mr.Difino Vitandonio, 7787, St-Dcnis, Montréal.P.Q.M.-Mr.Cyrille Allie, adresse inconnue-address unknown.Au rôle-on roll: M.-Mr.Sarto Dubuc.1158, Har- risson, Montréal-Sud-South, P.Q.M.-Mr.J.-A.Filiatrault.771, St-Georges, Jac- aues-Cartier, P.Q.e-Miss Katharine McKian, 238, Wilbrod, Ottawa.Ont.M.-Mr.Léo Kolber.132.St-Jacques-Ouest-St.James-West, Montréal.P.Q.Au rôle-on roll: M.Guy-F.Dubuc.1300, Blvd Rainville, Montréal.Sud-South.P.Q.Dame Emma Tousignant, vve en premières noces de C.-E.Manseau et l'épouse en secondes noces de Lionel J.Turcotte \u2014 Dame Emma Tousignant, widow by first marriage of C.E.Manseau and wife by second marriage of Lionel J.Turcotte.375.Blvd Taschereau, Jacques-Cartier, P.Q.Au rôle-on roll: M.-Mr.L.Peters c/o P.Thibodeau.90, Guillaume, Lowmeuil.P.Q.M.-Mr.Guy-F.Dubuc.1300, Blvd Rainvillo.Montréal-Sud-South.P.Q.M.-Mr.Robert E.Power, 2e Rue R.R.No 1 Elber-son, Penn.U.S.A.145-241.242, 254, 260 145-243, 244 145-247, 248.252, 253, 255, 256.145-259 145-249, 250, 251, 257, 258 145-245, 246 145-261 145-516, 617 145-714, 715 145-716.717 145-718.719 145-1038.1039 145-1040.1041 145-1057, 1058 115-1059, 1060 148-223 148-455, 456 148-457.458 148-459, 460, 461 148-468 148-471 148-155 148-154 148-152, 153 A distraire partie vendue à La Ville Jacques-Cartier, appert acte enregistré sous le numéro 118874.\u2014 To withdraw part sold to City of Jacques-Cartier, appears in registered dead under number 118874.148-258, 259 148-291, 292 148-295.296 148-397, 398, 400 148-399 148-394, 395 140-871 141, 520 145-174 140-929 141-444 141-445 141-446 141-509, 510 146-436, 437 140-1134, 1135 140-1197 à-to 1189 140-1200, 141-726 à 729 i: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 24th, 1956, Vol 88, No.47 3919 Folio Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immoveable M.-Mr.Joseph-Arthur Millette, 27, Blvd St-Paul.Shawinigan Falls, P.Q.City and District Land Development Co.Ltd.Au rôle-on roll: M.-Mr.Guy-F.Dubuc.1300, Blvd Rainville, Montréal-Sud-South, P.Q.M.-Mr.Sydney Collette, 122, King-Georges, Croydon.P.Q.M.-Mr.Charles Barmash, 8146, Berman, Montréal, P.Q.M.-Mr.Léo Kolber, 132, St-Jacques Oucst-St.James-West, Montréal.P.Q.City and District Land Development Co.Ltd.M.-Mr.Guy-F.Dubuc, 1300, Blvd Rainville Montréal.Sud-South.P.Q.City and District Land Development Co.Ltd.M.-Mr.Guy-F.Dubuc.1300, Blvd Dubuc, Montréal.Sud-South, P.Q.M.-Mr.André Leduc, 2305, Cartier, Jacques-Cartier.P.Q.M.-Mr.Léo Kolber, 132, St-Jacques, O.-W., Montréal, P.Q.M.-Mr.John Crzywara, 2249, Papineau, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Auréléan Téodorovici, adresse inconnue-address unknown.Au rôle-on roll: M.-Mr.Clément Téodorovici, 2222 Auger, Montréal, P.Q.M.-Mr.Auréléan Téodorovici, adresse inconnue-address unknown.Au rôle-on roll: M.-Mr.Clément Téororovici, 2222 Auger, Montréal, P.Q.Joseph Pichette et son épouse-and his wife Marie Cotton, 2CG8.Ste-Hélène, Jacques-Cartier, P.Q F.S.Mackay, adresse inconnue-address unknown M.-Mr.Joseph Charles Pichette, 2267, Delorimier.Jacques-Cartier, P.Q.Mr.-M.Sam Wruleswky, 5250, Park Ave., Montréal.P.Q.Damo Germaine Gingras, vve de-widow of Albert Gareau, adresse inconnue-address unknown.Henri Frechette et son épouse-and his wife Raymond Robichaud, 7454, Durocher, apt.6, Montréal, P.Q.Michel Adolphe Sauriol, 22S1, Ch.Chambly, Jacques-Cartier, P.Q.' M.-Mr.Joseph Richtone, 1003, Mahowing Av.Youngston, Ohio.U.S.A.M.-Mr.Adolphe Monbeig, adresse inconnu address unknown.Au rôle-on roll: M.-Mr.A.Sauriol, 2281, Ch.Chambly, Rd., Jacques-Cartier, P.Q.Independent Reaîtv Development Ltd.Au rôle-on roll: M.-Mr.A.Sauriol, 2281, Ch.Chambly, Rd., Jacques-Cartier.P.Q.Dame Tellie Cruchcstha, vve de-widow of Stefan Yasky; Joseph Yasky: Léo Yasky; Maurice Yasky; Stella Yaskv: Helen Yasky, 2062, St-Urbain, Montréal, P.Q.M.-Mr.Marcel Ouellettc, 11,841, Lamoureux.Montréal, P.Q.M.-Mr.Alfred Noël.455, Craig West, Chambre-Room 403.Montréal, P.Q.M.-Mr.Louis D.Freidman, 67, Center Street West, Beacon.N.Y.U.S.A.M.-Mr.Louis Polger, 4599, Royal Ave, Montréal.P.Q.M.-Mr.Léo Manseau, 5031 St-Hubert, Montréal.P.Q.M.-Mr.Roland Turgeon, adresse inconnue-address unknown.Mlle-Miss Eva Courtemanche, adresse inconnue-address unknown.Au rôle-on roll: M.-Mr.Victor Deschènes, 2186, Gauthier.Montréal, P.Q.Ben Copplo; Sol.Copple; Anne Copple, épouse de-wife of Robert Hirsch; Hilda Coople.épouse de-wife of McLean Sutow, adresse inconnue-address unknown.M.-Mr.John Crowe, 5029, Des Erables, Montréal.P.Q.M.-Mr.William Golden, 989, St-Antoine,lMont-réal, P.Q.145-550 140-1342 141-829 141-865 141-869, 870 145-73G, 737 145-738, 739 148-275.276, 277 148-335, \"336 118-337, 338 142-852, 853 14S-44 à-to 446 148-405.404 148-413, 414 148-410, 415 148-417, 418 148-419.420 148-426 148-427, 428 148-429, 430, 431 145-866.867 145-1063, 1064 145-1065, 1066 144-974 à 976, 145-1C69 145-1068 145-1071 à-to 1073 91-108, 109 91-306, 307 91-308 91-239 91-236, 237, 238 91-328 91-346, 347 91-166, 167 91-168, 169,170 91-260 à-to 263 91-267 91-272 91-360 91-370, 371 91-372 91-370, 371, 372 91-379, 280 92-210.211 92-148, 149 92-146.147 3920 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 24 novembre 1956, Tome 88, N° 47 Nom et adresse Name and address Description do l'immeuble Description of immoveable Mrs.Peter Laidlow, C14, Carleton, Montréal, P.Q.M.-Mr.Adrien Piché, fils-son, 203, Coyette, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.J.Aimé Martin, 321, Coyette, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Willie Lebeau, 2290, St-Alexandre, Jacques-Cartier, P.Q.Damo Marguerite Lcclair ct son époux-and bis husband Wilbrod Forget, adresse inconnuo-address unknown.M.-Mr.Henri Lavoie, 211 Desmarchais, Jacques-Cartier.P.Q.Dame Minnie Cohen, épouse de-wife of Sam Berish, adresse inconnue-address unknown.Au rôle-on roll: M.-Mr.A.Sauriol, 2281, Ch.Chambly, Rd., Jacques-Cartier, P.Q.Independent Realty Ltd., 1117, Ste-Cathcrine Ouest-West, Montréal, P.Q.Damo Pierrette Mayer, épouse de-wife of André Vincent, 374, St-Jean, Longueuil, P.Q.M.-Mr.Michael Kovshoff, 4820 Côte Ste-Catho-rine, Montréal, P.Q.M.-Mr.Rudolf Pukliez, adresse inconnue-addres.' unknown.Au rôle-on roll: M.-Mr.A.Sauriol, 22S1, Ch.Chambly, Rd., Jacques-Cartier, P.Q.M.»Mr.M.-A Sauriol, 2281, Ch.Chambly.Rd., Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Fernand Gagnon, 2830.Ilolt, Montréal, M.-Mr.J.Aimé Martin, 324, Coyette, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Fred Richman, 3998.Hotel-dc-Ville, Montréal, P.Q.M.-Mr.Willio Lebeau, 2180, Sr-Alexandre, Jneques-Carticr, P.Q.M.-Mr.Ambroise Dufour, Mont-Joly, comté dc-county of Matane, P.Q.M.-Mr.Guy.-F.Dubuc.1300, Blvd Rainville, Montréal-Sud-South, P.Q.M.-Mr.Léo Poirier, 2004, McGill, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Guy-F.Dubuc.1300, Blvd Rainville Montréa-Sud-South, P.Q.Dame Joseph E.Tuer, adresse inconnue-address unknown M.-Mr.Léo Kolber, 132, St-Jacqucs Ouest-West Montréal, P.Q.M.-Mr.Léon Sauvé, 3009, Grand Boulevard Mackayvillo, P.Q.City and District Land Development Co.Ltd.Au rôle-on roll: M.-Mr.Guy.-F.Dubuc, 1300, Blvd Rainville, Montréal-Sud-South, P.Q.Mlle-Miss Bernadette St-Pierrc, adresse inconnue-address unknown.Mercury Realties Inc.1470, Peel, Montréal, P.Q.Michel Adolphe Sauriol, 2281, Ch.Chambly.Jacques-Cartier, P.Q.City and District Land Development Corp.Ltd.Au rôle-on roll: Guy-F.Dubuc, 1300 Blvd Rainville, Montréal-Sud-South, P.Q.City and District Land Development Corp.Ltd.Au rôle-on roll: M.-Mr.Guy-F.Dubuc, 1300 Blvd Rainville, Montréal-Sud-South, P.Q.M.-Mr.Frank Miller, adresse inconnue-address unknown.Dame Florence Lamarre, épouse de-wife of R Payette, 1395, Ch.Chambly Rd., Jacques-Cartier, P.Q.Au rôle-on roll: M.-Mr.René Chrétien, 51, Huron Street, Toronto.Ont.Damo Florence Lamarre, épouse de-wife of R Payette, 1395, Ch.Chambly Rd., Jacques-Cartior.P.Q.M.-Mr.F.J.Tucker, 5942, Clanranald, Montréal, P.Q.92-144, 145 92-141 92-279 92-370, 377 92-80 92-199 à-to 202 92-287, 288 92-289 à-to 292 93-104, 105 93-220 à-to 229 93-270, 271 93-158 à-to 160 91-349 92-232, 233 92-280 92-281 92-181, 182 133-943, 944 135-16 135-129, 130 135-125 135-118 à-to 122 135-60.61 135-41 à-to 44 130-296 131-401, 400 131-4 131-6 131-149.150 131-72, 73, 74 131-10 131-17 123-689 85-256 à-to 258 85-261, 262 85-411 85-476.85-527, 85-529, 85-566, 85-568.85-570, 85-572, 85-574, 86-576, 85-578.85-580.86-1632 86-1612 k-to 413 477 528 530 567 569 671 573 576 577 579 581 , 1633 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 2J,th, 1956, Vol.88, No.47 3921 Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immoveable Dame F.Lamarre, 6p.-wife It.Payette, 1395, Ch.Chambly, ltd, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.R.J.W.Mack, 22, Neptune Avenue, Strathmore, P.Q.M.-Mr.Joan-Marc Bertrand,\" 907, Delorimier, Montréal-Sud-South, P.Q.N.O.Lindholum, 27, Lauder Road, Edimburgh Ecosse, Scotland.M.-Mr.Paul Robert, 1791, Lavallée, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Paul Péloquin, Adresse inconnue \u2014 Ad-dross unknown.Au rôle \u2014 On roll: M.-Mr.Paul Robert, 1791, Lavallée, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.E.Goorges Driver, 3243, St-Antoine Montréal, P.Q.M.-Mr.Fernand Gagnon, 1879, St-Alexandre, Jac- ques-Cartler, P.Q.Mlle-Miss Florida Harvey, 1218.Sto-Elizabcth.Montréal, P.Q.Alexandra Zawgorodnay, vve-widow Alexandre Makarow, 2122, St-Thomas, Jacques-Cartioa, P.Q.86-1583, 15S4 86-1124 86-1573 86-1570, 1569 86-1566.1565 Damo Florence Lnmarro épouse de-wife of R.86-1204, 1205 Payette.2395, Ch.Chambly ltd., Jacques-Cartier.P.Q.M.-Mr.Willie Limoges, 58, Wolfe.Jacques- 8 6-1605 Cartier, P.Q.Dame F.Lamarre, épouse de-wife of P.Payette, 86-1581, 1582 2395.Ch.Chambly ltd., Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Pierre Stabili, adresse inconnue-address unknown.Damo Anita Lovac, 4835 Mercier Apt.4, Montréal, P.O.Dame F.Lamarre, épouse de-wife of It.Payette, 2395.Ch.Chambly ltd., Jacques-Cartier, P.Q.Damo Annette Limoges, vve de fcu-wifo of the late Georges Boily, et-and André Boily, 5638, 18ièmo Avcnuc-18th Avenue, Rosemont, Montréal P.Q.M.-Mr.Fernand Biais, 2465, St-Charles, Montréal, P.Q.M.-Mr.Henri Cousincau, 1319, Ch.Chambly, ltd Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.G.W.Limoges, 60, Wolfe, Jacques-Cartier, M.-ivfV.Gaston Turgeon, 1331, Grant, Jacques-Cartier, P.Q.Dame Annette Limoges, ve do feu-wife of the late Georges Boily et-and André Boily, 5038, ISième Avenue Rosemont Montréal, P.Q.M.-Mr.Willie Limoges, 58, Wolfe, Jacques-Cartier.P.Q.Dame Florence Lamarre, épouse de-wife of It.Payette, 1395, Ch.Chambly ltd., Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Willio Limoges, 58, Wolfe, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Eugène Lafontaine, 1091, Blvd Nobert Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Jean-Marc Bertrand, 907, Delorimier Montréal-Sud-South, P.Q.Dame Henriette Bertrand, épouse de-wife of Henri Giroux, HO rue Marieville, Marieville, P.Q.M.-Mr.Armand Larivée, 395, St-Alexandre, Longueuil, P.Q.M.-Mr.Roland Paquin, 44, Montcalm, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Carmelo Jitto.697.Montcalm, R.R.No.1 Longueuil, P.Q.Damo F.Lamarre, épouse do-wife of R.Payette 1395, Ch.Chambly ltd., Jacques-Cartior, P.Q.M.-Mr.J.W.Limoges, 58, Wolfe, Jacques-Cartier, P.Q.Mllo-Miss Anita Levac, 4836 Mercier Appt-Apt.4 Montréal.P.Q.M.-Mr.Willio Limoges, 58, Wolfe, Jacques-Cartior, P.Q.M.-Mr.Michel Adolphe Sauriol et-and Highland Garden Ltd.2281, Ch.Chambly, Rd., Jacques-Cartier, P.Q.86-1564, 1563 86-1549A 86-959.960 86-961, 962 86-907 86-903, 904 86-901, 902 80-899 86-893 80-815, 840, 847 80-800, 861 86-517 86-518, 519 86-230 86-221, 222 86-647, 648, 649 86-651.65 86-1607 86-1606 86-1574 86-842 à-to 844 86-546.545, 544 à distraire desdits lots, la partie venduo appert à un acte enregistré sous le numéro 132335.\u2014 and 86-546, 545, 544 to withdraw from said lots, the part sold appears in registered deed under number 132335.86-543, 542, 541 85-472, 471, 470 86-1367, 1368 86-516, 515, 514 75-1153 86-1041, 1040 86-1043, 1042 133-555, 554, 132 P.17, 18 A distraire des lots 133-555 et 132-17 la partie vendue appert un acte enregistré sous le numéro 110542.\u2014 To withdraw from lots 133-555 and 132017 part sold appears in registered deed under number 110542.133-542 133-653 * 134-112 3922 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U novembre 1956, Tome 88, N° L7 Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immoveable M.-Mr.Paul Bouchard.265.St-Charles, O.-W.Ebngueuil, P.Q.M.-Mr.Guv-F.Dubuc.1300.Blvd Rainville, Montréal-Sud-South.P.Q.M.-Mr.Léo Poirier, 2064 McGill, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.F.J.Pruce.08, Arlington, Ottawa, Ont.M.-Mr.Guv-F.Dubuc, 1300, Blvd Rainville.Montréal-Sud-South, P.Q.M.-Mr.Fred J.Nowell, R.R.N° 1, Rawson, P.Q.M.-Mr.Saluste Lavery, 1375, St-Denis, Montréal, P.Q.M.-Mr.Guv-F.Dubuc.1300 Blvd Rainville, Montréal-Sud-South, P.Q.M.-Mr.Guv-F.Dubuc, 1300 Blvd Rainville, Montréal-Sud-South, P.Q.Au rôle\u2014On roll: M.-Mr.Damase Grisé, Adresse inconnue \u2014 Address unknown.M.-Mr.Salustre Lavery, 1375, St-Denis, Montréal, P.Q.M.-Mr.Ulrio Dion, 1551, Labonté, Jacques-Cartier, P.Q.Au rôle \u2014 On roll: Dame A.Bouthot-Levac, 460 Coteau-Rougc, Jacques-Cartier, P.Q.Dame Jeannine Hébert ép.-wife, Leopold Roy, St-Mathias, Co.Laprairie, P.Q.Dame Blanche Ouimet, ép.-wife, Arsène Michaud 350, St-Alexandre, Longueuil, P.Q.M.-Mr.Johny Ley, 3070, Barcklay Appt 2-Apt.2 Montréal, P.Q.M.-Mr.Albert Cormier, 1980, St-Alexandre, Jacques-Cartier, P.Q.M.-Mr.Guy-F.Dubuc.1300, Blvd Rainville, Montréal-Sud-South, P.Q.M.-Mr.Roger Chalifoux, 10365, Blvd St-Laurent ' .Montréal, P.Q.135-280 135-274 135-213 135-211 135-147, 146 135-145.144 135-345 135-262, 261 135-254, 255 135-248 135-240 ' 135-195, 196 136-249 136-236.235 137-95, 96 137-136, 135 135-232, 233 133-688, 689.690 \u2014- A distraire partie venduo appert à l'acte enregistèé sous lo numéro 130-953.135-167, 168 \u2014 A distraire parties vendues à la Voirie, appert à un acte enregistré sous le numéro 133865.\u2014 To withdraw parts sold to Dent, of Roads, appears in a registered deed under number 133865.135-439 Lesdits lots et parties de lots sont du cadastre officiel de la paroisse Saint-Antoine de Longueuil.Ils seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s'il y a lieu, sujets à tous les droits acquis de la cité de Jacques-Cartier et à tons servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes pouvant les affecter.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.La vente sera en ¦outre sujette aux dispositions de la Loi de la Commission municipale de Québec.Donné à Jacques-Cartier, ce 7ènie jour de novembre 1950.L'Officier en charge de la vente, 43675-46-2-0 C.-E.DION.The said lots and parts of lots are of the official cadastre of the parish of St.Antoine de Longueuil.They shall be sold with buildings creeled thereon, circumstances and dependencies, if any subject to all the acquired rights of the city of Jacques-Cartier and any servitudes both active and passive, apparent or unapparent which may affect them.\u2022 The purchase price of said immoveables shall be payable immediately.The sale moreover, shall be subject to the provisions of the Quebec Municipal Commission Act.Given at Jacques-Cartier, this 7th day of November 1956.G.-E.DIOX.43675-46-2-0 Officer in charge of sale.Département de l'Agriculture Industrie Laitière Commission* de l'Industrie Laitière de la Province de Québec Ordonnance N° 18-56 (Région d'Amos) Extrait des procès-verbaux des séances de la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Quéjpec.Séance du jeudi, le 8 novembre, 1956, tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à Montréal, à 10 heures du matin.Department of Agriculture Dairy Industry Dairy Industry Commission of the Province of Quebec Order No.18-56 (Region of Amos) Excerpt from the proceedings of the meetings of the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec.' Meeting of Thursday, November 8th, 1956, held in the office of the Dairy Industry Commission in Montreal, at 10 o'clock in the morning. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 24th, 1956, Vol.88, No.47 3923 Présents: MM.Omer-E.Milot, président, Joseph Hébert, Adrien Angers, J.-Albert Char-trand et Walter D.Lowe, commissaires, et Alphonse Savoie, secrétaire.ATTENDU que, depuis la dernière fixation des prix du lait en nature par la Commission dans le cours de l'année 1951, le coût de production du lait, de sa manipulation et de sa distribution a subi des hausses et qu'il en coûte plus cher pour l'outillage requis et la main-d'œuvre adéquate sur les fermes et dans les usines de pasteurisation; Attendu que, pour ces motifs, les marchands de lait et les producteurs ont demandé à la Commission une augmentation des prix du lait; Attendu que la Commission de l'Industrie Laitière doit fixer le prix du lait, en tenant compte de la valeur du produit, des conditions de sa production, de sa manipulation, de sa livraison et des conditions des divers marchés locaux, de façon à sauvegarder les intérêts des producteurs-, fournisseurs, des marchands de lait, des distributeurs de produits laitiers et des consommateurs; La Commission décrète ce qui suit: 1° La présente ordonnance s'applique à toute personne qui, directement ou indirectement, vend ou livre du lait dans les limites de la région d'Amos.2 e La région d'Amos comprend le territoire de la municipalité de la ville d'Amos, plus une zone d'un quart de mille en profondeur tout autour de ladite municipalité et les municipalités de la paroisse et de la ville de Senneterrc.3° Les marchands de lait, les sociétés coopératives et les syndicats coopératifs doivent payer à leurs fournisseurs-producteurs, pour chaque cent livres de lait qu'ils reçoivent de ceux-ci $4.79 net F.A.B.la place d'affaires dudit marchand et.à même cette somme payer à la Commission de l'Industrie Laitière de la Province de Québec, un demi-cent par cent livres de lait ainsi reçu.4° Sauf les dispositions de l'article 5 de la présente ordonnance, nul ne peut, dans les limites fie ladite région d'Amos offrir, vendre ou livrer du lait à des prix inférieurs à 12 cents la chopinc et 21 cents la pinte.5° Nul ne peut offrir, vendre ou livrer du lait à une épicerie, à un restaurant, à un hôtel, à une cantine militaire, à un marchand ou à tout autre établissement de commerce à des prix inférieurs à 0 cents le demiard, 11 cents la chopine, 19^2 cents la pinte et en bidon 76 cents le gallon.6° Nul ne peut offrir, vendre ou livrer du lait en bidon aux institutions de charité et aux hôpitaux à un prix inférieur à 74 cents le gallon.' es institutions auront le privilège d'acheter le lait en bouteille aux prix fixés pour le commerce du gros, soit: 11 cents la chopinc et 19^2 cents la pinte.7° Nul marchand de lait, société coopérative ou syndicat coopératif ne peut offrir vendre ou livrer du hit aux distributeurs de produits laitiers à un prix inférieur à 62 cents le gallon.8° La présente ordonnance annule l'ordonnau-ce \\'° 1S-52, et entrera en vigueur le premier décembre 1956.Le secrétaire de ladite Commission est chargé de la publication de la présente ordonnance dans la Gazette officielle de Québec.Signé: Omer-E.Milot, président, Joseph Hébert, commissaire, Adrien Angers, commissaire, J.-A.Chartrand, commissaire, Walter D.Lowe, commissaire.Certifié: Alphonse Savoie, secrétaire, 13758-0 Present: Messrs.Omer-E.Milot, President, Joseph Hébert, Adrien Angers, J.-Albert Chartrand and Walter D.Lowe, Commissioners, and Alphonse Savoie, Secretary.Whereas since 1951, when prices for milk for fluid consumption were last fixed, the cost of milk production, handling and distribution has increased as well as that of the adequate equipment and labour required on the farms and in the pasteurizing plants; Whereas for these reasons the milk dealers and producers have requested the Commission to increase milk prices; Whereas the Dariry Industry Commission must set the price of milk by taking into account the value of the product, the conditions under which it is produced, its handling, its delivery and the conditions of the various local markets, in order to protect the interests of the producers-suppliers, the milk dealers, the distributors of dairy products and the consumers; It is enacted as follows: 1.The present Order is applied to any person who, directly or indirectly, sells or delivers milk within the limits of the region of Amos.2.The region of Amos includes the town municipality of Amos, plus a radius of one quarter of a mile in width surrounding the territory of said town of Amos and the parish and town municipalities of Senncterre.3.Milk dealers, cooperative societies and cooperative syndicates must pay to their producers-suppliers for each hundred pounds of milk which they receive from them 84.79 net F.O.Ii.business place of said dealer, and out of this sum pay the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec, one-half cent for each hundred pounds of milk received.4.Save the provisions of article 5 of the present Order, no person shall, within the limits of said region of Amos offer, sell or deliver milk at prices inferior to 12 cents a pint and 21 cents a quart.5.No person shall offer, sell or deliver milk to a grocery, a restaurant, a hotel, a military canteen, a dealer or to any other business establishment at prices inferior to 6 cents a half-pint, 11 cents a pint, 19^2 cents a quart and in hulk 76 cents a gallon.6.No person shall offer, sell or deliver milk in bulk to charitable institutions or to hospitals at a price inferior to 74 cents a gallon.Those institutions will have the privilege of buying bottled milk at wholesale prices, that is 11 cents a pint and 193^ cents a quart.7.No milk dealer, cooperative %society or cooperative syndicate shall offer, sell or deliver milk to distributors of dairy products at a price inferior to 02 cents a gallon.8.The present Order cancels Order No.18-52, and shall come into force on the first December 1950.The Secretary of said Commission is charged with the publication of the present Order in the Quebec Official Gazette.Signed: Omer-E.Milot, President, Joseph Hébert, Commissioner, Adrien Angers, Commissioner, J.-A.Chartrand, Commissioner, Walter D.Lowe, Commissioner.Certified: Alphonse Savoie, Secretary.43758-0 3924 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, g/, novembre 1956, Tome 88, N° /,7 Commission de l'Industrie Laitière de la Province de Québec Ordonnance N° 27-5GA (Région de Lac St-Jean) Extrait des procès-verbaux des séances de la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec.Séance du mardi.20 novembre 1956, tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à Québec, à 10 heures du matin.Présents: MM.Omer-E.Milot, président, Joseph Hébert.Adrien Angers, J.-Albert Char-trand.et Walter I).Lowe, commissaires, Alphonse Savoie, secrétaire, et Cbarles-A.Gamache, c.r., conseiller juridique.La Commission décrète ce qui suit: 1° L'Ordonnance N° 27-50 publiée dans la Gazelle officielle de Québec du 27 octobre 1950 est amendée et.l'article 2 est remplacé par le suivant: 2° La région du Lac St-Jean comprend les municipalités suivantes: Les cités de Chicoutimi et d'Arvida, les villes de Cbicoutimi-Nord, de Bagotville, de Port-Alfred, de Kénogami, de Jonquières.d Aima, TED, a body politic and \\ corporate having its head office in Toronto and a place of business at Barville, in the district of Abitibi, distrainer vs FLORENT MARCHAND, formerly of Barville, in the district of Abitibi and now of unknown whereabouts, distrainee.NOTICE OF SALE The immoveable known and designated\"as being lot number 2B, Range VII, of the official cadastre for the township of Malartic, in the district of Abitibi.To be sold at the door of the Parochial Church of Rivière Héva.county of Abitibi-East, the TWENTY-SEVENTH day of DECEMBER 1950 at TEN o'clock in the forenoon.J.-ALFRED GAUTHIER, Sheriffs Office.Sheriff of Abitibi.Amos, this November 5, 1956.43761p47-2-o BEDFORD Canada, Province of Quebec District of Bedford Superior Court, I JEAN PLOURDE, owner of No.6860.\\ J \" a saw mill residing and I domiciled at Brome, district of Bedford, plaintiff vs GEORGE KUCENTY merchant of the city and'district of Montreal and KAROL GUTKIND, mechanic, of the city and district of Montreal, defendants.a) A plot of land of irregular shape, known and designated as being part of lot number two hundred and fifteen (Part No.215) of the official cadastre of the township of Brome, situated between the Yamaska River (south branch) and the public highway, leading to Cowansville; the said plot of land is bounded as follows; southwesterly, by the public highway, northwesterly, by a part of lot tow hundred and fifteen (P.215); northeasterly by, the Yamaska River, southeasterly, by a part of lot two hundred and fifteen (P.215);\" b) A plot of land of irregular form being part of lot two hundred and fifteen (P.215) of the official cadastre of the township of Brome; the said plot of land is bounded as follows; southwesterly, by the public highway, northwesterly, by a part of lot two hundred and fifteen (P.215) north easterly, by the Yamaska River; southeasterly, by a part of lot two hundred and fifteen (P.215).c) A plot of land of irregular shape situated on the northeasterly side of the Yamaska River 3904 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 2J, novembre 1956, Tome 88, N° J,7 sud étant le coin nord du lot deux cent quinze (P.215) du cadastre officiel du canton de Brome; Avec lc moulin à scie et toutes autres bâtisses se trouvant sur ledit immeuble et avec tout ce qui, dans le susdit moulin à scie et les autres bâtisses, se trouve immeuble par destination et .spécialement avec toutes les machines machine-outils ct tous les outils.Pour être vendu \"en bloc\" à la porte de l'église paroissiale Ste-Rose de Lima, en le vilhge de Sweetsburg.dis'rict de Bedford, le CINQUIEME jour de DECEMBRE 1956 à DEUX heures de l'après-midi.Le Député-shérif, Bureau du Shérif, ANTONIN BOURASSA.Palais de Justice, Sweetsburg, Que., 24 octobre 1956.43582-44-2-0 CHICOUTIMI Fieri Facias District de Chicoutimi Cour Supérieure, f \"RAN FA RE D'ARVIDA, N° 21,458 < ¦*\u2022 corporation légalement v constituée, ayant son siège social en la ci'é d'Arvida, district de Chicoutimi, demanderesse; vs JEAN SOLLBERGER, domicilié en la paroisse de St-Jean-Eudes, district de Chicoutimi, défendeur.Contre le défendeur: Tout ce terrain ou emplacement de forme triangulaire mesurrnt environ cent cinq pieds (105') du nord au sud, côté est, soixante-quinze pieds (75') de profondeur de l'est à l'ouest, côté nord, formant partie du lot numéro cinq (ptic N° 5), par le XlIIième rnog sud-ouest du cadastre officiel de la paroisse de Chicoutimi, le tout compris dans les bornes suivantes: vers l'est à un ruisseau passant par cet endroit ou encore à l'Aluminum Co.of Canada Ltd, vers le nord au terrain ci-après décrit, vers le sud-ouest, à l'acquéreur, lc tout s»ns bâti s?.* Un autre terrain mesurant soixante-quinze pieds (75') de largeur du nord au sud par la profondeur ci-après déterminée, formant également partie du lot numéro cinq (ptie N° 5) par le XlIIième rang sud-ouest, au cadastre officiel de la paroisse de Chicoutimi, compris dans les bornes suivantes: vers l'est à un ruisseau ou encore à l'Aluminum Co.of Canada Ltd, vers le nord à Eugène Pcdneault, vers l'ouest à la route St-Mathias, ct vers le sud au terrain décrit en premier lieu.Pour être vendus \"en bloc\" à la porte de l'église paroissiale de St-Jean-Eudes, JEUDI, le VINGT-SEPTIÈME jour du mois de DÉCEMBRE 1956, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, RENÉ DELISLE.Chicoutimi, le 20 novembre 1956.43762-47-2-o hull District de Hull Cour de Magistrat, ( t ES COMMISSAIRES N° 22043.
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.