Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 3 août 1957, samedi 3 (no 31)
[" Tome 89, N° 31 2723 Vol.89, No.31 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Quebec, samedi 3 août 1957 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1957.Québec, le 22 juin 1957.L'Imprimeur de la Reine, 45197-25-10-o RÊDEMPTI PARADIS.PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, August 3rd, 1957 RECEEPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate dealy for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1957.Quebec, June 22nd, 1957.RÊDEMPTI PARADIS, 45197-25-10-o Queen's Printer.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance ù: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 2724 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S août 1957, Tome 89, N° SI insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.\u2014 5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces: Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Fçuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement : $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie 3ue la matière n'est ni de notre composition ni e notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, REDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.31753 \u2014 1-52 Lettres patentes (P.G.11911-57) Airbonne Equipment Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze juin 1957, constituant en corporation: William Alston Campbell, de Montréal-Ouest, Rupert Charles Thomas Harris, de Dorval et William Desmond Thomas, de la ville de Beacons-field, tous trois avocats, pour les objets suivants : the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoird, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: S7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure reers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.31753 \u2014 1-52 Letters Patent (A.G.11911-57) Airbonne Equipment Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of June, 1957, incorporating: William Alston Campbell, of Montreal West, Rupert Charles Thomas Harris, of Dorval, and William Desmond Thomas, of the town of Beaconsfield, all three advocates, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol 89, No.31 2725 Fabriquer et exercer le commerce d'avions, instruments et accessoires utilisés dans l'aviation et projectiles guidés de toutes sortes, sous le nom de \"Airborne Equipment Limited\", avec un capital total de $100,000, divisé en 50,000 actions ordinaires de Si chacune et 5,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Outre-mont, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45182 P.FRENETTE.(P.G.11834-57) A.Poirier, Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit juin 1957, constituant en corporation: Antonio Poirier, Jean-Guy Poirier et Raymond Poirier, tous marchands, de Saint-Laurent, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de quincaillerie, sous le nom de \"A.Poirier, Ltée\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 610, Boulevard Ste-Croix, St-Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11946-57) Apple Valley Construction Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six juin 1957, constituant en corporation: Edmond Auclair, de Otterburn Park, Roméo Plante et Jean Charbonneau, tous deux de St-Hilaire, tous entrepreneurs, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Apple Valley Construction Co.\", avec un capital total de §100,000, divisé en 200 actions privilégiées de S100 chacune et en 8,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Hilaire, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11955-57) Arrow Realties Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1957, constituant en corporation: William San ville Aaron, de St-Laurent, David Harry Wood, de Westmount et Henri Wilfrid Laurier, de St-Lambert, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme agents d'immeubles, sous le nom de \"Arrow Realties Corporation\", avec un capital total de $2,500, divisé en 250 actions ordinaires de $10 chacune.To manufacture and deal in aircraft, aircraft instruments and accessories and guided missiles of all kinds, under the name of \"Airborne Equipment Limited\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 50,000 common shares of $1 each and into 5,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Outremont, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11834-57) A.Poirier, Ltee Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of June, 1957, incorporating: Antonio Poirier, Jean-Guy Poirier and Raymond Poirier, all merchants, of Saint-Laurent, for the following purposes: To operate the industry and business dealing in hardware, under the name of \"A.Poirier, Ltée\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 shares of S100 each.The head office of the company will be at 610 Ste-Croix Boulevard, St-Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11946-57) Apple Valley Construction Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of June, 1957, incorporating: Edmond Auclair, of Otterburn Park, Roméo Plante and Jean Charbonneau, both of St-Hilaire, all contractors, for the following purposes: To carry on business as general building contractors, under the name of \"Apple Valley Construction Co.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 200 preferred shares of $100 each and into 8,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Saint-Hilaire, judicial district of St-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(G.G.11955-57)' Arrow Realties Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1957, incorporating: William San ville Aaron, of St.Laurent, David Harry Wood, of Westmount, and Henri Wilfrid Laurier, of St.Lambert, all three advocates, for the following purposes : To carry on business as real estate agents, under the name of \"Arrow Realties Corporation1*, with a total capital stock of $2,500, divided into 250 common shares of $10 each. 2726 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S août 1957, Tome 89, N° SI Le siège social de la compagnie sera à 754 rue Wellington, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(P.G.11903-57) Baie Ungava Prospecteurs Limitée (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettras patentes, en date du dix-sept juin 1957, constituant en corporation: Wilbur Ralph Slater, Barnabas William Nixon Apple, Kenneth Gordon Rupert Gwynne-Timothy, tous procureurs, de Toronto, Ontario, pour les objets suivants: Fnire des recherches et des explorations afin de découvrir des mines et des minerais, y compris le gaz naturel, pétrole, huile et leurs produits et sous-produits et les négocier, soils le nom de \"Baie Ungava Prospecteurs Limitée\", (No Personal Liability), avec un capital total de §300,000, divisé en 30,000 actions de S10 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant, du prix qu'ils auront paye ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Québec* district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur 'général, le dix-sept juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(P.G.12075-57) Bel-Air Leather Goods Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf juin 1957, constituant en corporation : André Dion, industriel, de Levis, Paul LeBœuf et Maurice Hébert, tous deux comptables, de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de valises, coffres, boîtes et meubles, sous le nom de \"Bel-Air Leather Goods Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 546, rue Darling, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-o P.FRENETTE.(P.G.12027-57) Belmont Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf juin 1957, constituant en corporation: Abraham Sinister, Bernard Diamond, tous deux avocats, de Montréal, et Jason Ruby, avocat, d'Outremont, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une corporation de terrains, construction, amélioration et développement; et celles de eourtiers en immeubles, sous The head office of the company will be at 754 Wellington Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11903-57) Baie Ungava Prospecteurs Limitée (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of June, 1957, incorporating: Wilbur Ralph Slater, Barnabas William Nixon Apple, Kenneth Gordon Rupert Gwynne-Timothy, all solicitors, of Toronto, Ontario, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals including natural gas, petroleum, oil and their products and by products and to deal with the same, under the name of \"Baie Ungava Prospecteurs Limitée\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $300,000, divided into 30,000 shares of $10 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsability in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12075.57) Bel-Air Leather Goods Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of June, 1957, incorporating: André Dion, industrialist, of Levis, Paul LeBoeuf and Maurice Hébert, both accountants, of Quebec, for the following purposes: To operate and industry and business dealing in trunks, chests, boxes and furniture, under the name of \"Bel-Air Leather Goods Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 546 Darling St., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12027-57) Belmont Development Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of June, 1957, incorporating : Abraham Sinister, Bernard Diamond, both advocates, of Montreal, and Jason Ruby, advocate, of Outre-mont, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction, improvement and development corporation; to carry on business as real estate brokers, under QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 2727 le nom de \"Belmont Development Corporation\", avec un capital total de 810,000, divisé en 25 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 75 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45182 P.FRENETTE.(P.G.12020-57) Benoît Morin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf juin 1957, constituant en corporation : Donat Morin, Benoît Morin, industriels, tous deux de Montmagny, et Jean Poirier, comptable agréé, de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme hôteliers et restaurateurs, sous le nom de \"Benoît Morin Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montmagny, district judiciaire de Montmagny.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45182-0 P.FRENETTE.(P.G.11970-57) Canuck Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit juin 1957, constituant en corporation: Auguste Vincent, de St-Lambert, J-Claude No-lin et René Talbot, tous deux de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs et sous-entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Canuck Construction Inc.\", avec un capital divisé en 100 actions communes sans valeur au pair et en 395 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune, et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de 84,500.Le siège social de la compagnie sera 507, Place d'Armes, suite 306, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11719-57) Champion Litho Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept juin 1957, constituant en corporation: Maurice Paiement, lithographe, Gertrude Paiement, épouse séparée de biens dudit Maurice Paiement, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Yvan Simundic, lithographe, et ITanna Simundic, épouse séparée de biens dudit Yvan Simundic, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous de Montréal, pour les objets suivants: the name of \"Belmont Development Corporation\", with a total capital stock of 810,000, divided into 25 common shares of a par value of 8100 each and into 75 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12020-57) Benoît Morin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of June, 1957, incorporating: Donat Morin, Benoît Morin, industrialists, both of Montmagny, and Jean Poirier, chartered accountant, of Quebec, for the following purposes: To carry on business as hotel and restaurant keepers under the name of \"Benoît Morin Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at Montmagny, judicial district of Montmagny.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of June.1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11970-57) Canuck Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of June, 1957, incorporating: Auguste Vincent, of St.Lambert, J.Claude Nolin and René Talbot, both of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on business as general contractors and sub-contractors under the name of \"Caauck Construction Inc.\" with a divided capital stock of 100 common shares without par value and into 395 preferred shares ôf a par value of 8100 each and the amount of the capital stock with which the company shall start its operations shall be 84,500.The head office of the company will be at 507 Place d'Armes, suite 306, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11719-57) Champion Litho Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, beraing date the Seventeenth day of June, 1957, incorporating: Maurice Paiement, lithographer, Gertrude Paiement, wife separate as to property of the said Maurice Paiement, and duly authorized by him for these present purposes, Yvan Simundic, lithographer, and Hanna Simundic, wife legally separate as to property of the said Yvan Simundic, and duly authorized by him for these purposes, all of Montreal, for the following purposes: 2728 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 août 1957, Tome 89, N° 31 Faire affaires comme imprimeurs, publicistes, photographes et lithographes, sous le nom de \"Champion Litho Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 150 actions communes de $100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11890-57) Charlevoix Video Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt juin 1957, constituant en corporation: Claude Lemieux, commerçant, Raymonde Villeneuve Lemieux, ménagère, épouse contractuel-lement séparée de biens dudit Claude Lemieux, majeur, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Gilles Breton, technicien, tous de Baie St-Paul, pour les objets suivants: Installer et exploiter un système d'antenne communautaire de télévision, sous le nom de \"Charlevoix Video Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 29%, rue St-Jean-Baptiste, Baie St-Paul, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le vingt juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11920-57) Clouette & Sternthal Automobiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit juin 1957, constituant en corporation: Henri-Paul Lemay, Bernard LeBel, tous deux avocats, de Montréal, et Paul-Édouard Ross, avocat, de Verdun, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'automobiles et autres moyens de transport; faire affaires comme garagistes et quincailliers, sous le nom de \"Clouette & Sternthal Automobiles Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées de $100 chacune et en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11816-57) Club de Chasse et de Pêche Maska Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt juin 1957, constituant en corporation: Léo-Paul Robert, marchand de bois, de La Providence, Léon Marchesseault, épicier, de Ville St-Joseph, et Leopold St-Amand, expéditeur, de-de St-Hyacinthe, pour les objeU suivants: To carry on business as printers, publicists photographers and lithographers, under the name of \"Champion Litho Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 150 common shares of $100 each and into 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11890-57) Charlevoix Video Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth ¦day of June, 1957, incorporating: Claude Lemieux, dealer, Raymonde Villeneuve Lemieux, housewife, wife contractually separate as to property of the said Claude Lemieux of full age, and duly authorized by him for these present purposes, and Gilles Breton, teclmician, of Baie St.Paul, for the following purposes: To install and operate a community television antenna system, under the name of \"Charlevoix Video Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 29H.St.Jean Baptiste St., Baie St-Paul, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11920-57) ' Clouette & Sternthal Automobiles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of June, 1957, incorporating: Henri-Paul Lemay, Bernard LeBel, both advocates, of Montreal, and Paul-Édouard Ross, advocate, of Verdun, for the following purposes: To operate an industry and business dealing in automobiles and other means of transportation : to carry on business as garage-keepers and hardware dealers, under the name of \"Clouette & Sternthal Automobiles Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 preferred shares of $100 each and into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11816-57) Club de Chasse et de Pêche Maska Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of June, 1957, incorporating: Léo-Paul Robert, lumber merchant, of La Providence, Léon Marchesseault, grocer, of the Town of St.Joseph, and Leopold St-Armand, shipper, of St.Hyacinthe, for the following purposes; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 2729 Promouvoir l'esprit sportif en ce qui concerne la chasse et la pêche dans le district de St-Flyacinthe et aider à faire observer les lois et les règlements concernant la protection du poisson et du gibier dans la province, sous le nom de \"Club de Chasse et de Pêche Maska Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Damase, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le vingt juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11793-57) Daigle Tire Service Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mai 1957, constituant en corporation: Charles-Thomas Doddridge, marchand, de Sillery, Charles-Auguste Daigle, vulcanisateur, de Charlesbourg, et Maxime Langlois, avocat, de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes; exercer l'industrie et le commerce d'automobiles et autres moyens de transport, sous le nom de \"Daigle Tire Service Limited\", avec un capital total de 820,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 245, 2ième rue, Limoilou, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mai 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11853-57) District Development Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un juin 1957, constituant en corporation: Claude Guérin, avocat, d'Outremont, Maurice Johnson, avocat, Claire Groulx, Yvette Marcoux et Madeleine Clermont, secrétaires, filles majeures, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers et agents d'immeubles et d'assurances, sous le nom de \"District Development Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions d'une valeur de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Château -guay, district judiciaire de Beauhamois.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-o P.FRENETTE.(P.G.11965-57) D.T.D.Construction Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six juin 1957, constituant en corporation : Adrien-R.Paquette, avocat, Françoise Frégeau, secrétaire, célibataire majeure, tous deux d'Ahuntsic, et Denise Racicot, secrétaire, céliba- To promote a sporting spirit in that which concerns hunting and fishing in the district of St.Hyacinthe and to help observe laws and regulations concerning the protection of fish and game in the province, under the name of \"Club de Chasse et de Pêche Maska Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Saint-Damase, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11793-57) Daigle Tire Service Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of May, 1957, incorporating: Charles-Thomas Doddridge, merchant, of Sillery, Charles-Auguste Daigle, vulcanizer, of Charlesbourg, and Maxime Langlois, advocate, of Quebec, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers; to operate an industry and deal in automobiles and other means of transportation, under the name of \"Daigle Tire Service Limited\" with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 245, 2nd street, Limoilou, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of May, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11853-57) District Development Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of June, 1957, incorporating: Claude Guérin, advocate, of Outremount, Maurice Johnson, advocate, Claire Groulx, Yvette Marcoux, and Madeleine Clermont, secretaries, spinsters, all four of Montreal, for tlie following purposes: To operate as brokers and agents in real estate and insurance, under the name of \"District Development Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of a value of $10 each.The head office of the company will be at Chateauguay, judicial district of Beauhamois.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11965-57) D.T.D.Construction Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of June, 1957, incorporating: Adrien R.Paquette, advocate, Françoise Frégeau, secretary, spinster of full age, both of Ahuntsic, and Denise Racicot, secretary, spinster of full age, of St- 273U UA££j1 i £j ut t n ir.i.i.r.un, ^ucdcv, yueuec, o août îaoi, i ome ott, iy ' oi taire majeure, de St-Eustache-sur-le-Lac, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"D.T.D.Construction Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-o P.FRENETTE.(P.G.12058-57) Eagle Crest Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux juin 1957, constituant en corporation: John J.Wasserman, avocat, de Westmount, Harold S.Freeman, Irving J.Halperin, tous deux avocats et Dorothy Martel, sténographe, fille majeure, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements aux fins de réaliser des revenus sur iceux, sous le nom de \"Eagle Crest Investment Corp.\", avec un capital-actions divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair, 1,000 actions privilégiées première catégorie d'une valeur au pair de $1 chacune et 440 actions privilégiées seconde catégorie d'une valeur au pair de $100 chacune et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $9,500.Le siège social de la compagnie sera a Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt -deux juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.Eustache-sur-le-Lac, for the following purposes: To carry on business as general building contractors, under the name of \"D.T.D.Construction Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be a! Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12058-57) Eagle Crest Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of June, 1957, incorporating: John J.Wasserman, advocate, of Westmount, Harold S.Freeman, Irving J.Halperin, both advocates, and Dorothy Martel, stenographer, spinster of the full age of majority, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company for the purpose of earning the income thereof, under the name of \"Eagle Crest Investment Corp.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without nominal or par value, 1,000 first preferred shares of a par value of $1 each and 440 into second preferred shares of a par value of $100 each, and the amount with which the company will commence it's operations will be $9,500.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11795-57) (A.G.11795-57) Eastern Oil Well Cementing and Testing Eastern Oil Well Cementing and Testing Limited Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1957, constituant en corporation: Thomas Palmer Howard, de Ville Mont-Royal, Ian Caldweel Stalker, de Westmount et Louis Cameron Des Bois, de Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à forer, entretenir, éprouver et cimenter des puits d'huile et de gaz naturel; faire le commerce de pétrole, gaz naturel, leurs produits et sous-produits, sous le nom de '.'Eastern Oil Well Cementing and Testing Limited\", avec un capital total de $20,-000, divisé en 19,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(P.G.12013-57) Eddy's Sportwcar Mfg Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1957, incorporating: Thomas Palmer Howard, of the Town of Mount Royal, Ian Caldwell Stalker, of Westmount, and Louis Cameron Des Bois, of Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of drilling, servicing, testing and cementing oil and natural gas wells; to deal in petroleum and natural gas and the products and by-products thereof, under the under the name of \"Eastern Oil Well Cementing and Testing Limited\", with a total capital stock of $20,000, divided into 19,000 preferred shares of a par value of $1 each and into 1,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12013-57) Eddy's Sportwear Mfg Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 2731 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze juin 1957, constituant en corporation: Boris Garmaise, Cyril Edgar Schwisberg, avocats, et Ida Larocque, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Confectionner et faire le commerce d'articles vestimentaires de toutes sortes, sous le nom de \"Eddy's Sportswear Mfg Co.Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 jetions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 15482 P.FRENETTE.(P.G.11885-57) Electrovector Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date «lu trente et un mai 1957, constituant en corporation: Louis Freedman, avocat et conseil en loi de la Reine, de la ville de Côte St-Luc, Irwin Aaron Frankel, avocat, de Ville Mont-Royal et Sadie Gersovitz, secrétaire, fille majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et exercer le commerce de systèmes et contrôles de chauffage, moteurs électriques et dispositifs et fournitures électriques, sous le nom de \"Electrovector Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 448 Boulevard Des Laurentides, Pont Viau, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un mai 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(P.G.11951-57) Fides Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze juin 1957, constituant en corporation: Max Liverman, Leonard Liverman, et Julius Briskin, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires 'l'une compagnie de terrains, de construction et d'amélioration, sous le nom de \"Fides Development Corporation\", avec un capital total de $20,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 850 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire'de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 15482 P.FRENETTE.(P.G.11950-57) Forward Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of June, 1957, incorporating: Boris Garmaise, Cyril Edgar Schwisberg, attorneys, and Ida Larocque, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel of all kinds, under the name of \"Eddy's Sportswear Mfg Co.Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11885-57) Electrovector Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of May, 1957, incorporating: Louis Freedman, advocate and Queen's Counsel, of the town of Cote St.Luc, Irwin Aaron Frankel, advocate, of the town of Mount Royal, and Sadie Gersovitz, secretary, spinster of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in heating systems and controls, electric motors ' and electrical appliances and accessories, under the name of \"Electrovector Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and into 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 448 Des Laurentides Blvd., Pont Viau, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of May, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11951-57) Fides Development Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of June, 1957, incorporating: Max Liverman, Leonard Liverman and Juluis Briskin, all advocates, of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Fides Development Corporation\", with a total capital stock of 820,000, divided into 100 common shares of a par value of 850 each and into 300 preferred shares of a par value of 850 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11950-57) Forward Development Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth 2732 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1957, Tome 89, N° 81 du quinze juin 1957, constituant en corporation: Max Liverman, Leonard Liverman et Julius\" Briskin, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Forward Development Corporation\", avec un capital total de $20,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $50 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(P.G.12081-57) Gérard Thibcault, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt juin 1957, constituant en corporation: Gérard Thibeault, René Thibeault et Claude Thibeault, tous fourreurs, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme fourreurs, sous le nom de \"Gérard Thibeault, Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et en 390 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-o P.FRENETTE.(P.G.11470-57) Gravelle's Esso Service Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit juin 1957, constituant en corporation: Paul Gravelle, garagiste, dame Millicent Gravelle, ménagère, épouse séparée de biens dudit Paul Gravelle, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de Dorval, et John G.Mulligan, C.A., de Senneville, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes, sous le nom de \"Gravelle's Esso Service Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Dorval, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-o P.FRENETTE.(P.G.11865-57) Grenier Spring Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf juin 1957, constituant en corporation: Evariste Grenier, industriel, Bernard Grenier, comptable, et Jacques Morais, notaire, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: day of June, 1957, incorporating: Max Liverman, Leonard Liverman and Julius Briskin, all advocates, of Montreal, for the following purpose,-: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Forward Development Corporation\", with a total capital stock of $20,000, divided into 100 common shares of a par value of $50 each and into 300 preferred shares of a par value of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12081-57) Gérard Thibeault, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of June, 1957, incorporating: Gérard Thibeault, René Thibeault and Claude Thibeault, all furriers, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as furriers, under the name of \"Gérard Thibeault, Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $10 each and into 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11470-57) Gravelle's Esso Service Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tin-Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of June, 1957, incorporating: Paul Gravelle, garage-keeper, dame Millicent Gravelle, housewife, separate as to property of the said Paul Gravelle, and duly authorized by him as to these presents, both of Forval, and John (i.Mulligan, C.A.of Senneville, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers, under the name of \"Gravelle's Esso Service Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Dorval, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11865-57) Grenier Spring Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of June, 1957, incorporating: Evariste Grenier, industrialist, Bernard Grenier, accountant, and Jacques Morais, notary, all three of Montreal, for the following purposes; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1967, Vol.89, No.31 2733 Faire affaires comme garagistes; exercer le commerce d'automobiles et autres moyens de transport, sous le nom de \"Grenier Spring Inc.\", avec un capital total de $75,000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, rlistrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11887-57) Hôtel Champlain Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un mai 1957, constituant en corporation: Madame Albert Dufour, veuve d'Albert Dufour, hôtelière, Georges Dufour, gérant d'hôtel, et Joseph Dufour, commis, tous trois de Chicoutimi, pour les objets suivants: Faire affaires comme hôteliers, sous le nom de \"Hôtel Champlain Inc.\", avec un capital total de $200,000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et en 1,500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un mai 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, -45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11884-57) Huntingdon Transport Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept juin 1957, constituant en corporation: James MacNair Smellie, garagiste, Harold Wattie, mécanicien, et Austin Murray, commis, tous trois de Huntingdon, pour les objets suivants: Exercer le commerce du transport de passagers et de marchandises, sous le nom de \"Huntingdon Transport Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Huntingdon, district judiciaire de Beauhamois.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11862-57) Immeubles Marquette Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf juin 1957, constituant en corporation: Luc Geoffroy, avocat, de Chambly, Robert Dulude, avocat, de Dorion, Réjane Schmidt, secrétaire, fille majeure, de Verdun, et Maurice-S.Hébert, avocat, de Belle vue, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Immeubles Marquette Realties To carry on business as garage-keepers; to operate a business dealing in automobiles and other means of transportation, under the name of \"Grenier Spring Inc.\", with a total capital stock of S75.000, divided into 250 common shares of a par value of 8100 each and into 1,000 preferred shares of par value of S50 each.The-head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11887-57) Hôtel Champlain Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of May, 1957, incorporating: Madame Albert Dufour, widow of Albert Dufour, hotel-keeper, Georges Dufour, hotel manager, and Joseph Dufour, clerk, all three of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on business as hotel-keepers, under the name of \"Hôtel Champlain Inc.\", with a total capital stock of S200,000, divided into 500 common shares of 8100 each and into 1,500 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this thirtv-first day of May, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11884-57) Huntingdon Transport Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of June, 1957, incorporating: Jnmes MacNair Smellie, garage-keeper, Harold Wattie, mechanic, and Austin Murray, clerk, all three of Huntingdon, for the'following purposes: To operate a business dealing in the transportation of passengers and merchandise, under the name of \"Huntingdon Transport Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Huntingdon, judicial district of Beauhamois.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 .Acting Deputy Attorney General.(A.G.11862-57) Immeubles Marquette Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of June, 1957, incorporating: Luc Geoffroy, advocate, of Chambly, Robert Didude, advocate, of Dorion, Réjane Schmidt, secretary, spinster, of Verdun, and Mauricc-S.Hébert, advocate of Bellevue, for the following purposes: To operate a business dealing in immoveables; to carry on business as general building contractors under the name of \"Immeubles Marquette 2734 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, S août 1967, Tons 89, N° SI Inc.\", avec un capital divisé en 100 actions sans valeur au pair ou nominale et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $500.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11990-57) Imperial Converters Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dé\"Québec des lettres patentes, en date du quatorze juin 1957, constituant en corporation: Albert Malouf, Peter Sborteno, avocats, tous deux de Ville Mont-Royal, Olga Chaban, secrétaire, fille majeure, de Rosemont et John Ciaccia, avocat, de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et exercer le commerce de vêtements et toutes autres sortes de tissus pour vêtements, sous le nom de \"Imperial Converters Co.Ltd.\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 500 actions ordinaires de 8100 chacune, 100 actions privilégiées catégorie \"A\" de $100 chacune et 4,000 actions privilégiées catégorie \"B\" de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 7386 rue St-Hubert, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(P.G.12042-57) Jonel Realty Corp.?Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un juin 1957, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, avocat, Anne Zifkin et Sonya Schneyer, toutes deux secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction et-amélioration, sous le nom de \"Jonel Realty Corp.\", avec un capital total dé 840,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 340 Édifice Dominion Square., Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(P.G.11999-57) La Comédie Canadienne Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq juin 1957, constituant en corporation: Gratien Gélinas, producteur de théâtre, Roméo Carie, comptable agréé, et Henri-Paul Lemay, avocat, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Realties Inc.\", with a capital stock divided into 100 shares without nominal or par value and the amount with which the company shall start its operations is $500.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11990-57) Imperial Converters Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of June, 1957, incorporating: Albert Malouf, Peter Shortcno, advocates, both of the town of Mount Royal, Olga Chaban, secretary, spinster of the full age of majority, of Rosemont, and John Ciaccia, advocate, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel and all other kinds of materials for wearing for wearing apparel, under the name of \"Imperial Converters Co.Ltd.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 500 common shares of $100 each, 100 preferred shares Class \"A\" of 8100 each and into 4,000 preferred shares Class \"B\" of S10 each: The head office of the company will be at 7386 St.Hubert Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12042-57) Jonel Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of June, 1957, incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Anne Zifkin and Sonya Schneyer, both secretaries, spinsters of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Jonel Realty Corp.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at 340 Dominion Square Bldg., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 -Acting Deputy Attorney General.(A.G.11999-57) La Comédie Canadienne Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of June, 1957, incorporating: Gratien Gélinas, theatre producer, Roméo Carle, chartered accountant, and Henri-Paul Lemay, advocate, all three of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 2735 Produire toutes œuvres dramatiques, artistiques ou musicales, ainsi que tous autres genres de spectacles, les monter et les présenter au public par le truchement du théâtre, du cinéma, de la radio, de la télévision ou de tous autres moyens de représentations; acquérir ou céder tous droits, concessions ou privilèges relatifs à ces œuvres ou spectacles, sous le nom de \"La Comédie Canadienne Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en G.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 81 chacune et en 940 actions privilégiées d'une valeur nu pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 ' P.FRENETTE.(P.G.11861-57) La Compagnie Laurent Roy Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf juin 1957, constituant en corporation: Laurent Roy, industriel, Bella P.Roy, ménagère, épouse commune en biens dudit Laurent Roy, et Roch Maheux, commis, tous trois de St-Georges, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en construction, sous le nom de \"La Compagnie Laurent Roy Limitée\", avec un capital total de $125,000, divisé en 1,250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Georges, district judiciaire de Beaucc.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11847-57) Le Comptoir Industriel Incorporé Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf mai 1957, constituant en corporation: Gaston Lefcbvre, agent manufacturier, Charles-Eugène Frenette, comptable agréé, et Léonie Giroux Lefebvre, ménagère, épouse séparée de biens de J.-Homère Lefebvre, et dûment' autorisée par lui aux fins des présentes, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de produits, articles et marchandises faits, en tout ou en par-tic, de cuir, caoutchouc, métal, métalloïde, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textile, verre et leurs sous-produits, de produits comestibles, chimiques et de beauté, sous le nom de \"Le Comptoir Industriel Incorporée\", avec un capital divisé en 370 actions privilégiées de $100 chacune et en 600 actions ordinaires sans valeur au pair ou nominale, et le montant avec lequel la compagnie pourra commencer ses opérations sera de $6,700.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf mai 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.To produce all dramatic, artistic or musical works, as well as all kinds of performances, to stage them and present them to the public by means of the theatre, cinema, radio, television or by any other means of performance; to acquire or cede all rights, concessions or privileges relative to these shows or performances, under the name of \"La Comédie Canadienne Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 6,000 common shares of a par value of $1 each and into 940 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11861-57) La Compagnie Laurent Roy Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of June, 1957, incorporating: Laurent Roy, industrialist, Bella P.Roy, housewife, wife common as to property of the said Laurent Roy, and Rock Maheux, clerk, all three of St-Georges, for the following purposes: To carry on business as building contractors under the name of \"La Compagnie Laurent Roy Limitée\", with a total capital stock of $125,000, divided into 1,250 shares of $100 each.The head office of the company will be at St-Georges, judicial district of Beauce, Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11847-57) Le Comptoir Industriel Incorporé Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of May, 1957, incorporating: Gaston Lefebvre, manufacturing agent, Charles-Eugène Frenette, chartered accountant, and Léonie Giroux Lefebvre, housewife, wife separate as to property of J.Homère Lefebvre, and duly authorized by him for these present purposes, all of Montreal, for the following purposes: To operate an industry and business dealing in products, articles and merchandise made, in whole or in part, of leather, rubber, metal, metalloid, wood, paper, nylon, plastic, fur, textile, glass and their by-products, of edible, chemical and beauty products, under the name of \"Le Comptoir Industriel Incorporée\", with a capital stock divided into 370 preferred shares of $100 each and into 600 common shares without nominal or par value, and the amount with which the company may start its operations shall be of $6,700.' The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of May, 1957.i P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General. 2736 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S août 1967, Tome 89, N° Si (P.G.11969-571 Les Édifices Laflèche Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit juin 1957, constituant en corporation: Gilles Rouleau, avocat, de Baie Comeau, Gontran Rouleau, avocat, et Jacques Rouleau, comptable, tous deux d'Hauterive, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Les Édifices Laflèche Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions communes de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Haute-rive, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.12046-57) Les Immeubles Handel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date dû dix-huit juin 1957, constituant en corporation : Paul Racine, industriel, de Québec, Thomas E.Anderson, trust officer, et Roger Létourneau, avocat, tous deux de Sillery, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Les Inmeubles Randel Inc.\",.avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $50 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-o P.FRENETTE.(P.G.11507-57) Les Placements Tracy Incorporé Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi dea compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six juin 1957, constituant en corporation : Henri St-Germain, teneur de livres, Annette Martel, commis, célibataire, et Paul-A.Bélanger, avocat, tous de Sorel, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et de portefeuille (\"holding\"), sous le nom de \"Les Placements Tracy Incorporé\", avec un capital total de $45,000, divisé en 450 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sorel, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11854-57) L.et Ph.Morello Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a (A.G.11969-571 Les Édifices Laflèche Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of June, 1957, incorporating: Gilles Rouleau, advocate, of Baie Comeau, Gontran Rouleau, advocate, and Jacques Rouleau, accountant, both of Hauterive, for the following purposes: To carry on business as general building contractors under the name of \"Les Édifices Laflèche Inc.\" with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Hauterive, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12046-57) Les Immeubles Randel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of June, 1957, incorporating: Paul Racine, industrialist, of Quebec, Thomas E.Anderson, trust officer, and Roger Létourneau, advocate, both of Sillery, for the following purposes: To operate a business dealing in immoveables; to carry on business as general building contractors under the name of \"Les Immeubles Randel Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of a par value of $50 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11507-57) Les Placements Tracy Incorporé Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty -sixth day of June, 1957, incorporating: Henri St-Germain, book-keeper, Annette Martel, clerk, bachelor, and Paul-A.Bélanger, advocate, all of Sorel, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company under the name of \"Les Placements Tracy Incorporé\", with a total capital stock of $45,000, divided into 450 shares of $100 each.The head office of the company will be at Sorel, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11854-57) L.et Ph.Morello Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 2737 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf juin 1957, constituant en corporation: Philip Morello, lien ri-M.Bcaulieu, tous deux entrepreneurs, et Raphaël Esposito, notaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Paire affaires comme entrepreneurs généraux en construction ,sous le nom de \"L.et Ph.Morello Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11552-57) Levis Stores Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mai 1957, constituant en corporation: Benoît Gagné, voyageur de commerce, Charles Fortier, industriel, et Yves Roy, notaire, tous trois de Lévis, pour les objets suivants: Exercer le commerce de grains, céréales et autres produits agricoles, sous le nom de \"Levis Stores Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 66-b, rue Commerciale, Lévis, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mai 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11947-57) Mainland Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze juin 1957, constituant en corporation: Max Liverman, Leonard Liverman et Julius Briskin, tous trois avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, de construction et d'amélioration, sous le nom de \"Mainland Development Corporation\", avec un capital total de $20,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $50 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(P.G.11994-57) Martel Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit juin 1957, constituant en corporation: Pierre-L.Martel, constructeur, Bernard Dubé, comptable, et André Mayer, tous de Montréal, pour les objets suivants: been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of June, 1957, incorporating: Philip Morello, Henri M.Beaulieu, both contractors, and Raphael Esposito, notary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on as general building contractors, under the name of \"L.et Ph.Morello Lie\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each, and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11552-57) Levis Stores Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of May, 1957, incorporating: Benoît Gagné, commercial traveller, Charles Fortier, industrialist, and Yves Roy, notary, all three of Levis, for the following purposes: To operate a business dealing in grains, cereals and other farm products, under the name of \"Levis Stores Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into-400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 66-b Commerciale St.Levis, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of May, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11947-57) Mainland Development Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of June, 1957, incorporating: Max Liverman, Leonard Liverman and Julius Briskin, all three advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Mainland Development Corporation\", with a total capital stock of $20,000, divided into 100 common shares of a par value of $50 each and into 300 preferred shares of a par value of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11994-57) Martel Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of June, 1957, incorporating: Pierre J.Martel, builder, Bernard Dubé, accountant, and André Mayer, all of Montreal, for the following purposes: 2738 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S août 1957, Tome 89, N° SI Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Martel Construction Inc.\", avec un capital total de §50,000, divisé en 50 actions communes de $100 chacune et en 450 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 6719, Boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-o P.FRENETTE.(P.G.11953-57) Matériaux de Construction Melocheville Limitée Melocheville Builders Supplies Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit juin 1957, constituant en corporation: Louis-Philippe Dumouchel, vendeur, de Pointe Pilon, en la paroisse de Saint-Timothée, Aloysius Lavigueur, comptable, et Jacqueline Giroux, secrétaire, tous deux de Beauhamois, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction et exercer le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Matériaux de Construction Melocheville Limitée \u2014 Melocheville Builders Supplies Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera rue Principale, Melocheville, district judiciaire de Beauhamois.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, \u2022 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.12063-57) Mazana Lumber Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf juin 1957, constituant en corporation: Jean-Marie Aubé, marchand, Bernadette T.Aubé, ménagère, épouse séparée de biens dudit Jean-Marie Aubé, tous deux de St-Sua-veur-des-Monts, et Gustave Aubé, mécanicien, de Pont-Viau, pour les objets suivants: Faire affaires comme .marchands de bois, sous le nom de \"Mazana Lumber Lie\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Sau-veur-des-Monts, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.12043-57) Merlin Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un juin 1957, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, avocat, Anne Zifkin et Sonya Scheneyer, toutes deux secrétaires, filles To carry on business as general building contractors under the name of \"Martel Construction Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 50 common shares of $100 each and into 450 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 6719 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11953-57) Matériaux de Construction Melocheville Limitée Melocheville Builders Supplies Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of June, 1957, incorporating: Louis-Philippe Dumouchcl, salesman, of Pointe Pilon, in the parish of Saint-Timothée, Aloysius Lavigueur, accountant, and Jacqueline Giroux, secretary, both of Beauharnois, for the following purposes: To carry on business as general building c«n-tractors and to operate a business dealing in materials under the name of \"Matériaux de Construction MelochevillG Limitée \u2014 Melocheville Builders Supplies Limited\", with a total capital stoc, of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Principale St.Melocheville, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12063-57) Mazana Lumber Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of June, 1957, incorporating: Jean-Marie Aubé, merchant, Bernadette T.Aubé, housewife, wife separate as to property of the said Jean-Marie Aubé, both of St.Suaveur-des-Monts, and Gustave Aubé, mechanic, of Pont-Viau, for the following purposes : To carry on business as lumber merchants under the name of \"Mazana Lumber Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at St-Sauveur-des-Monts, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12043-57) Merlin Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of June, 1957, incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Anne Zifkin and Sonya Schneyer, both secretaries, spinsters of the full QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 2739 majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Merlin Realty Corp.\", avec un capital total de S-10,000, divisé ën 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 340 Edifice Dominion Square, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(PG.11922-57) Montreal Leaseholds Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois juin 1957, constituant en corporation: Harry Blank, Conrad Shatner, Baruch Pollack, tous trois avocats, et Grace Freeman, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce général d'immeubles et exercer dés affaires comme entrepreneurs et constructeurs généraux, sous le nom de \"Montreal Leaseholds Corp.\", avec un capital total de $8,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 4,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 15482 P.FRENETTE.(P.G.11694-57) Nova Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept juin 1957, constituant en corporation: John Palov, administrateur, Michael Midlick) gérant de bureau, tous deux de Ville Mont-Royal et Andrew Michalko, agent d'immeubles, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une corporation de terrains, de construction et de développement, sous le nom de \"Nova Development Corporation\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 8255 Boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(P.G.11613-57) Omega Plastic Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six juin 1957, constituant en corporation: Marcel Picard, médecin-vétérinaire, de L'Epiphanie, André Ayotte, contremaître, et Joseph Warmington, gérant de ventes, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Merlin Realty Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 340 Dominion Square Bldg., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11922-57) Montreal Leaseholds Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of June, 1957, incorporating: Harry Blank, Conrad Shatner, Baruch Pollack, all three advocates, and Grace Freeman, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To deal generally in real estate and carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Montreal Leaseholds Corp.\", with a total capital stock of $8,000, divided into 4,000 common shares of a par value of $1 each and into 4,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11694-57) Nova Development Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of June, 1957, incorporating: John Palov, Executive, Michael Midlick, office manager, both of the Town of Mount Royal, and Andrew Michalko, real estate agent, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and development corporation, under the name of \"Nova Development Corporation\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 8255 St.Lawrence Blvd., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11613-57) Omega Plastic Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of June, 1957, incorporating: Marcel Picard, veterinary, doctor, of L'Epiphanie, André Ayotte, foreman, and Joseph Warmington, sales ¦ manager, both of Montreal, for the following purposes: Exercer l'industrie et le commerce de produits, articles et marchandises faits, en tout ou en partie de matière plastique, sous le nom de \"Omega Plastic Ltée\", avec un capital total de $80,000, divisé en 500 actions communes de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à L'Epiphanie, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-o P.FRENETTE.\u2022(P.G.11819-57) Par - A - Gaz Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mai 1957, constituant en corporation: Lucien Paradis.Jean-Paul Paradis, Guy Paradis, marchands, de Ste-Foy, et Robert Paradis, marchand, de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes; exercer l'industrie et le commerce d'automobiles et autres moyens de transport, sous- le nom de \"Par -A - Gaz Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 175, rue de la Couronne, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mai 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11902-57) Parkview Manor Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I^oi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit juin 1957, constituant en corporation: Gerald Stein, administrateur, Judith Fink, sténographe, fille majeure, et Daniel Kingstone, étudiant, tous de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et faire le commerce et le négoce d'immeubles ou intérêts en iceux et en particulier acquérir ou autrement faire le commerce et mettre à profit certaines propriétés immobilières situées à 1255 rue Sherwood Crescent en 1250 rue Lombard Crescent, Ville Mont-Royal, P.Q., sous le nom de \"Parkview Manor Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(P.G.11992-57) Paul Morency Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt juin 1957, constituant en corporation: Paul Morency, industriel, Gilles Gagnon, et To operate an industry and business dealing in products, articles and merchandise made wholly or in part of plastic matter, under the name of \"Omega Plastic Ltée\", with a total capital stock of $80,000, divided into 500 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at L'Epiphanie, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11819-57) Pap- A - Gaz Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of (lu-Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of May, 1957, incorporating: Lucien Paradis, Jean-Paul Paradis, Guy Paradis, mer-chants, of Ste-Foye, and Robert Paradis, nier-chant, of Quebec, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers; to operate an industry and deal in automobiles and other means of transportation, under the name of \"Par - A - Gaz Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 175 Crown Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of May, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11962-57) Parkview Manor Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued hy the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of June, 1957.incorporating: Gerald Stein, executive < Judith Fink, stenographer, spinster, and Daniel Kingstone, sutdent, all of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with real estate or interests therein and in particular to acquire or otherwise deal with and turn to account certain immoveable properties located at 1255 Sherwood Crescent Street, and 1250 Lombard Crescent Street, Town of Mount Royal, P.Q., under the name of \"Parkview Manor Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 preferred shares having a par value of $100 each und into 100 common shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11992-57) Paul Morency Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of June, 1957, incorporating: Paul Morency, industrialist, Gilles Gagnon and J.Claude \u2022V, J.-Claude Gagnon, avocats, tous de Rimouski, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de liqueurs douces, sous le nom de \"Paul Morency Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé* en 250 actions ordinaires de $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le vingt juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.12104-57) Pima Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq juin 1957, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant, David Henry Holland, avocat, tous deux de St-Lambert, Alexander Gordon Yeoman, commis en Loi, Clifford George Meek, teneur de livres, tous deux de Montréal, Cecil Bruce Cooke, secrétaire, de Brucy, Charles Eric Humphrey, teneur de livres, de Verdun et James Harold Stafford, commis, de Belœil Station, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Pima Mines Limited\" (No Personal Liability), avec un capital total de 8100,000, divisé en 100,000 actions d'une valeur au pair de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45182 P.FRENETTE.(P.G.11804-57) Produits Drummond Products L^fe Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept juin 1957, constituant en corporation : Laurent Jutras, notaire, René Forcier, comptable et Gilbert Beaudet, commis-voyageur, tous trois de Drummondville, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce produits liquides, en cire ou en pâte servant à laver, nettoyer et polir, sous le nom de \"Produits Drummond Products ktéê ' avec un capital total de S30.000, divisé en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $20 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1512, Boulevard Mercure, St-Simon-de-Drummond, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 .P.FRENETTE.Gagnon, advocates, all of Rimouski, for the following purposes: To operate an industry and business dealing in soft drinks under the name of \"Paul Morency Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 250 common shares of $100 each and into 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Rimouski, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12104-57) Pima Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of June, 1957, incorporating: Ernest William Mockridge, manager, David Henry Holland, advocate, both of St.Lambert, Alexander GordoQ Yeoman, law clerk, Clifford George Meek, bookkeeper, both of Montreal, Cecil Bruce Cooke, secretary, of Brucy, Charles Eric Humphrey, bookkeper, of Verdun, and James Harold Stafford, clerk, of Belœil Station, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Pima Mines Limited\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $100,000, divided into 100,000 shares of a par value of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11804-57) Produits Drummond Products Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of June, 1957, incorporating: Laurent Jutras, notary, René Forcier, accountant, and Gilbert Beaudet, commercial traveller, all three of Drummondville, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in liquid products of wax or paste to be used for washing, cleaning and polishing, under the name Ltd \" of \"Produits Drummond Products ' with a capital stock of a total par value of $30,000, divided into 100 preferred shares of a par value of $100 each, and into 1,000 common shares of a nominal value of $20 each.The head office of the company will be at 1512 Mercure Boulevard, St-Simon-de-Drummond, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General. 2742 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S août 1957, Tome 89, N° SI (P.G.11996-57) Ralliement du Grand Montréal Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze juin 1957, constituant en corporation sans capital-actions: Lucien Croteau, agent d'affaires, Pierre Simoneau, agent d'assurances, Médéric Gervais, comptable, et Guido Corbo, secrétaire, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir le bien-être général de la population de Montréal, sous le nom de \"Ralliement du Grand Montréal Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-Q P.FRENETTE.(P.G.11471-57) René A.Pigeon et Associés Ltée René A.Pigeon and Associates Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize juin 1957, constituant en corporation: Real Marcoux, avocat, de Dorval, Rita Dufresne et Estelle Thérien, secrétaires, filles majeures, toutes deux de Montréal, pour les objets suivants : Faire affaires comme courtiers et agents en assurances, sous le nom de \"René A.Pigeon et Associes Ltée \u2014 René A.Pigeon and Associates Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions de $100 chacune et en 300 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11697-57) Rosaire Pilon Cie.Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept juin 1957, constituant en corporation: Rosaire Pilon, entrepreneur-électricien, Vincent Blouin, entrepreneur en construction, tous deux de Ste-Geneviève, et Harry J.Erdrich, avocat, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en électricité et en construction, sous le nom de' \"Rosaire Pilon Cie.Ltée\", avec un capital divisé en 300 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Geneviève, comté de Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(A.G.11996-57) Ralliement du Grand Montréal Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of June, 1957', to incorporate as a corporation without share capital: Lucien Croteau, business agent, Pierre Simoneau, insurance agent, Médéric Gervais, accountant, and Guido Corbo, secretary, all four from Montreal, for the following purposes: To promote the general welfare of the population of Montreal, under the name of \"Ralliement du Grand Montréal Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11471.-57) René A.Pigeon et Associés Ltée René A.Pigeon and Associates Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of June, 1957, incorporating: Real Marcoux, advocate, of Dorval, Rita Dufresne, and Estelle Thérien, secretaries, of full age, both of Montreal, for the following purposes: To operate as brokers and insurance agents under the name of \"René A.Pigeon et Associés Ltée \u2014 René A.Pigeon and Associates Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 shares of $100 each and into 300 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11697-57) Rosaire Pilon Cie.Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of June, 1957, incorporating: Rosaire Pilon, electrical contractor, Vincent Blouin, building contractor, both of Ste-Geneviève, and Harry J.Erdrich, advocate, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as building and electrical contractors, under the name of \"Rosaire Pilon Cie.Ltée\", with a capital stock divided into 300 common shares of a par value of $100 each and into 100 preferred shares of a par valiie of S100 each.The head office of the company will be at Sainte-Geneviève, county of Jacques-Cartier, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 2743 (P.G.11284-57) Star Home Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a ('¦té accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze avril 1957, constituant en corporation: Arthur Tremblay, Roland Tremblay, constructeurs, et Jean-Marc Mayrand, agent d'immeubles, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Star Home Construction Ltd.\", avec un capital total de $200,000, divisé en 15,000 actions communes de $10 chacune et en 500 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1965, rue Bélanger, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze avril 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.12099-57) Terrasse Beloeil Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept juin 1957, constituant en corporation: André Ducharme, avocat, de Pont-Viau, Jean Filiatreault, avocat, Jeannine Brunette et Claire Morin, toutes deux secrétaires, filles majeures et usant de leurs droits, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction et compagnie de placements et d'immeubles, sous le nom de \"Terrasse Beloeil Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 574, rue bemoyne, Belœil Station, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11998-57) Théâtre de la Comédie Canadienne Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de-la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq juin 1957, constituant en corporation: Gratien Gélinas, producteur de théâtre, Roméo Carie, comptable agréé, Henri-Paul bemay, avocat, tous trois de Montréal, Ghislaine Gagné, secrétaire, fille majeure, de Laval-des-Rapides, et Claire Bissonnette, secrétaire, fille majeure, de Verchères, pour les objets suivants: Construire, acheter, louer, échanger, exploiter ou vendre des théâtres, des cinémas, des salles de concerts, de conférences ou de récréation, ainsi que des studios de radiodiffusion ou de télévision, sous le nom de \"Théâtre de la Comédie Canadienne Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $5 chacune et en 7,000 actions privilégiées de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(A.G.11284-57) Star Home Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of April, 1957, incorporating: Arthur Tremblay, Roland Tremblay, builders, and Jean-Marc Mayrand, real estate agent, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general building contractors under the name of \"Star Home Construction Ltd.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 15,000 common shares of $10 each and into 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 1965 Bélanger St., East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of April, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12099-57) Terrasse Beloeil Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of June, 1957, incorporating: André Ducharme, advocate, of Pont-Viau, Jean Filiatreault, advocate, Jeanine Brunette and Claire Morin, both secretaries, spinsters in full use of their rights, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general building contractors and an investment and real estate business, under the name of \"Terrasse Belœil Inc.\", with a total capital stock of $40,000,' divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 574 Lemoyne Street, Belœil Station, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11998-57) , Théâtre de la Comédie Canadienne Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of June, 1957, incorporating: Gratien Gélinas, theatre producer, Roméo Carle, chartered accountant, Henri Paul Lemay, advocate, all three of Montreal, Ghislaine Gagné, secretary, spinster, of Laval-des-Rapides, and Claire Bissonnette, secretary, spinster, of Verchères, for the following purposes: To build, purchase, rent, exchange, operate or sell theatres, cinemas, concert, lecture or recreation halls, as well as studios for radio or television broadcasting, under the name of \"Théâtre de la Comédie Canadienne Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 85 each and into 7,000 preferred shares of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth dav of June, 1957.P FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General, (P.G.11706-57) The California Standard Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1957, constituant en corporation: Lucien Beauregrad, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Llewellyn S.Rcycraft, Roland-G.Chauvin, tous deux avocats, Joseph-O.Brunelle, comptable, tous quatre de Montréal, Léon La-lande, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Pierre Le Beau, avocat, tous deux d'Outremont, Jean Brisset, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de la ville de Lery et Paul T.W.Beck, gérant, de Ville Mont-Royal, pour les objets suivants: Acquérir, exploiter et développer des terrains, claims miniers, droits de mines, puits de pétrole, d'huile et de gaz, terrains d'huile et de gaz et autres propriétés immobilières, sous le nom de \"The California Standard Company Limited\", avec un capital-actions divisé en 500 actions sans valeur nominale ou au pair et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie commencera ses activités sera $2,500.Le siège social de la compagnie sera à 240 ouest, rue St-Jacques, chambre 33, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(P.G.11584-57) Tremblay & Néron Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze juin 1957, constituant en corporation: Gilles Rouleau, avocat, de Baie Comeau, Gontran Rouleau, avocat, et Jacques Rouleau, comptable, tous deux d'Hauterive, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Tremblay & Néron Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions communes de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Baie Comeau, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le quinze juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-o P.FRENETTE.(P.G.11982-57) Union Palace Tavern Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la* province de Québec des lettres patentes, en date du vingt juin 1957, constituant en corporation: Fernande Aiidy Laporte, ménagère, épouse séparée de biens de Louis Laporte, Jacques Morais, notaire, tous deux de Montréal, et Lionel Leroux, notaire, d'Outremont, pour les objets suivants: Faire affaires comme taverniers, hôteliers et restaurateurs, sous le nom de \"Union Palace Tavern Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune._ Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.(A.G.11706-57) The California Standard Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the sixth day of June, 1957, incorporating: Lucien Beauregard, advocate and Queen's Counsel, Llewellyn S.Rcycraft, Roland-G.Chauvin, both advocates, Joseph-O.Brunelle, accountant, all four of Montreal, Léon Lalande, advocate and Queen's Counsel, Pierre Le Beau, advocate, both of Outremont, Jean Brisset, advocate and Queen's Counsel, of the Town of Lery, and Paul T.W.Beck, manager, of the Town of Mount Royal, for the following purposes: To acquire, dispose of and develop lands, mining claims, mineral rights, petroleum, oil and gas wells, oil and gas lands and other real property, under the name of \"The California Standard Company Limited\", with a capital stock divided into 500 shares without nominal or par value and the amount of capital stock with which the company will commence its operations will be $2,500.The head office of the company will be at 240 St.James Street, West, Room 33, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11584-57) Tremblay & Néron Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of June, 1957, incorporating: Gilles Rouleau, advocate, of Baie Comeau, Gontran Rouleau, advocate, and Jacques Rouleau, accountant, both of Hauterive, for the following purposes: To carry on business as general building contractors, under the name of \"Tremblay & Néron Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Baie Comeau, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11982-57) Union Palace Tavern Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of June, 1957, incorporating: Fernande Audy Laporte, housewife, wife separate as to property of Louis Laporte, Jacques Morais.notary, both of Montreal, and Lionel Leroux, notary of Outremount, for the following purposes: To carry on business as tavern-hotel and restaurant keepers, under the name of \"Union Palace Tavern Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 21 Ab Daté du bureau du Procureur général, le vingt juin 1957: L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11900-57) Utility Bag Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit juin 1957, constituant en corporation : Irwin S.Brodie, Cyrill E.Schwisberg, tous deux avocats, et Sonya Schneyer, sécréta're, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de sacs en plastique, cotton, cuirette, nylon, toile, rayonne et saran, sous le nom de \"Utility Bag Co.Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5770 boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(P.G.11909-57) Vermont Automobiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit juin 1957, constituant en corporation: Jacques Leblanc, vendeur, Janine Soudeyns Leblanc, marchande publique, épouse con-tractuellement séparée de biens dudit Jacques Leblanc, et Joseph Mancini, comptable, tous de .Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'automobiles et autres moyens de transport; faire affaires comme garagistes et agents d'immeubles, sous le nom de \"Vermont Automobiles Inc.\", avec un capital total de $25,000, divisé en 250 actions communes de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 10480, rue Lajeunesse, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-juit juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, lô482-o P.FRENETTE.(P.G.11842-57) 126 St.Pierre Realty Inc.AvisVest donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du 10 juin 1957, constituant en corporation: Samuel Leon Mendelsohn, avocat et Conseil en Ix)i de la Reine, de Westmount, Leo Rosentzveig, avocat, et Bertha Mendelson, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de terrains et immeubles, sous le nom de \"126 St.Pierre Realty Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 9,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11900-57) Utility Bag Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of June, 1957, incorporating: Irwin S.Brodtc, Cyril E.Schwisberg, both advocates, and Sonya Schneycr, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in plastic, cotton, leatherette, nylon, duck, rayon and saran bags, under the name of \"Utility Bag Co.Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 5770 St.Lawrence Blvd., judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11909-57) Vermont Automobiles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of June, 1957, incorporating: Jacques Leblanc, salesman, Janine .Soudeyns Leblanc, public merchant, wife contractually separate as to property of the said Jacques Leblanc, and Joseph Mancini, accountant, all of Montreal, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in automobiles and other means of transportation; to operate as garage-keepers and real estate agents, under the name of \"Vermont Automobiles Inc.\", with a total capital stock of $25,000, divided into 250 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at 10480 Lajeunesse St., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11842-57) 126 St.Pierre Realty Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of June, 1957, incorporating: Samuel Leon Mendelsohn, advocate and Queen's Counsel, of Westmount, Leo Rosentzveig, advocate, and Bertha Mendelson, secretary, spinster of the full age of majority, both of Montreal, for the following purposes: To deal in land and real estate, under the name of \"126 St.Pierre Realty Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and into 9,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-0 Acting Deputy Attorney General. 2746 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, S août 1957, Tome SB, JV\" SI Lettres patentes supplémentaires (P.G.10991-57) Fonderie Beloeil Limitée Beloeil Foundry Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-huit mai 1957, à la compagnie \"La Fonderie de Belœil, Limitée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 14 décembre 1937, 1° changeant son nom en celui de \"Fonderie Belœil Limitée \u2014 Belœil Foundry Limited\"; 2° augmentant son capital de $20,000 à $40,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 650 actions ordinaires de $25 et en 150 actions privilégiées de $25.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mai 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11609-57) Foyer Villa Maria Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quatorze juin 1957, à la corporation \"Foyer Villa Maria Inc.\", étendant ses pouvoirs à celui d'établir et administrer une infirmerie-hôpital et emportant le montant des biens immobiliers que ladite corporation peut posséder de $200,000 à $700,000.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.10195-57) Hi-Standard Products Ltd.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires en date du septième jour de juin 1957 à la compagnie \"Hi-Standard Products Ltd.\", 1° convertissant 10,000 actions privilégiées de $10 en 10,000 actions privilégiées, première catégorie de $10; 2° créant et émettant 4,000 actions ordinaires de $10, de son capital-actions en 4,000 actions privilégiées, seconde catégorie de $10; 3° subdivisant 1,000 actions ordinaires de $10, de son capital-actions en 10,000 actions ordinaires de $1.Daté du bureau du Procureur général, ce 7e jour de juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482 P.FRENETTE.(P.G.11629-57) Kirk Trading Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quatre juin 1957, à la compagnie \"Kirk Trading Corporation\", 1° réduisant son capital de $40,000 à $20,000: le ca- Supplementary Letters Patent (A.G.10991-57) Fonderie Beloeil Limitée Beloeil Foundry Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May twenty-eighth, 1957, to the company \"La Fonderie de Belœil, Limitée\", incorporated into a corporation under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of December 14, 1937, 1.changing its name into that of \"Fonderie Belœil Limitée \u2014 Belœil ¦ Foundry Limited\"; 2.increasing its capital stock from $20,000 to $40,000: the additional capital stock being divided into 650 common shares of $25 and into 150 preferred shares of $25.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of May, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11609-57) Foyer Villa Maria Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated June fourteenth, 1957, to the corporation \"Foyer Villa Maria Inc.\", extending its powers to that of establishing and managing a nursing-hospital and in carrying the amount of immoveable property that the said corporation may own from $200,000 to $700,000.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth, day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10195-57) Hi-Standard Products Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent bearing date the 7th day of June, 1957, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec to the company \"Hi-Standard Products Ltd.\", 1.converting 10,000 preferred shares of $10 into 10,000 first preferred shares of $10; 2.creating and issuing 4,000 common shares of $10 of its capital stock as 4,000 second preferred shares of 810; 3.subdividing 1,000 common shares of $10 of its capital stock into 10,000 common shares of $1.Dated at the office of the Attorney General, this 7th day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11629-57) Kirk Trading Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated June fourth, 1957, to the company \"Kirk Trading Corporation\", 1.reducing its capital stock from $40,000 to $20,000: the cancelled capittl stock QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 2747 oital-actions annulé étant divisé en 200 actions ordinaires de SI00; 2° augmentant son capital ainsi réduit de $20.000 à $120,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 1,000 actions privilégiées de $100.Daté du bureau du Procureur général, le quatre juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11655-57) Laviolette & Brosseau Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix-sept mai 1957, à la compagnie \"Laviolette & Brosseau Inc.\", 1° réduisant son capital de $49,900 à $25,000: le capital-actions annulé étant divisé en 249 actions ordinaires de $100; 2° augmentant son capital ainsi réduit de $25,000 à $75,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 500 actions privilégiées de $100.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept mai 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11926-57) Tannerie Cantin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du onze juin 1957, à la compagnie \"Tannerie Cantin Ltée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 21 décembre 1956, ebangenat son nom en celui de \"Tannerie Cantin Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le onze juin 1957.L'Assistant-proeureurgénéral suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.(P.G.11874-57) The Empire Waterproof Clothing Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieuttnint-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du onze juin 1957, à la compagnie \"The Empire Waterproof Clothing Company\", augmentant son capital de $99,000 à $139,000: le capital-act ion s additionnel étant divisé en 400 actions privilégiées de $100.Daté du bureau du Procureur général, le onze juin 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 45482-0 P.FRENETTE.being divided into 200 common shares of $100; 2.increasing its capital stock thus reduced from $20,000 to $120,000: the additional capital stock being divided into 1,000 preferred shares of $100.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11655-57) Laviolette & Brosseau Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May seventeenth, 1957, to the company \"Laviolette & Brosseau Lie\", 1.reducing its capital stock from $49,900 to $25,000: the capital stock cancelled being divided into 249 common shares of $100; 2.increasing its capital stock thus reduced from $25,000 to $75,000: the additional capital stock being divided into 500 preferred shares of $100.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of Mav, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11926-57) Tannerie Cantin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated June eleventh, 1957, to the company \"Tannerie .Cantin Ltée\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of December 21, 1956, changing its name into that of \"Tannerie Cantin Inc.\".\u2014 Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11874-57) The Empire Waterproof Clothing Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by tjie Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated June eleventh, 1957, to the company \"The Empire \"Waterproof Clothing Company\", increasing its capital stock from $99,000 to $139.000: the additional capital stock being divided into 400 preferred shares of $100.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of June, 1957.P.FRENETTE, 45482 Acting Deputy Attorney General.Action en séparation de biens Action for Separation as to Property Canada, Province de Québec, district de Mon- Canada, Province of Quebec, district of Montréal, Cour Supérieur, N° 423,933.treal, Superior Court, No.423,933.Dame Emma Plante, épouse commune en 1 Dame Emma Plante, wife common as to pro- biens de Paul Emile Turcotte, domiciliée et perty of Paul Emile Turcotte, domicilied and résidant au N° 4467 rue Messier, à Montréal, dis- residing at No.4467 Messier St., at Montreal, trict de Montréal, demanderesse, vs Paul Emile district of Montreal, plaintiff, vs Paul Emile Turcotte, domicilié et résidant au N° 4467 de la Turcotte, domiciled and residing at 4467 Mes- 2748 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 8 août 1957, Tome 89, N 81 rue Messier, à Montréal, district de Montréal, défendeur.AVIS Une action en séparation de biens a été intentée contre le défendeur le 24 juillet 1957.Montréal, le 24 juillet 1957.Les Procureurs de la demanderesse, GRÉGOIRE, DANSEREAU, DAOUST, VERNIER, DUCEPPE.DUGUAY 45491-0 & ALLAIRE.Arrêté en Conseil ARRÊTE EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 729 Québec, le 18 juillet 1957.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant certains actes administratifs du département de la chasse et des pêcheries.Concernant la chasse à la perdrix.Attendu que la gelinotte à queue aiguë est encore rare; Attendu que la population de perdrix grise et de perdrix de savane se maintient à un niveau tel qu'une saison de chasse est justifiée; Attendu que pour ta bonne administration, il y a lieu d'effectuer certains changements dans la saison de chasse à la perdrix.Vu l'article 65 du chapitre 153 des Statuts refondus de Québec, 1941.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre de la chasse et des pêcheries: Que la chasse à la gelinotte à queue aiguë soit prohibée en 1957; Qu'il soit défendu de chasser la perdrix grise et la perdrix de savane sauf du dernier samedi de septembre au quatrième dimanche de novembre, ces deux dates incluses, aux conditions suivantes: Personne ne pourra tuer ou capturer plus de cinq (5) perdrix par jour; personne ne pourra a-voir en sa possession plus que la prise légale de trois (3) jours; personne ne pourra avoir de perdrix en sa possession après le six (6) janvier suivant la saison de chasse précédente; Que la partie de l'arrêté en conseil numéro 695, en date du 4 juillet 1956, concernant la gelinotte à queue aiguë et la perdrix grise et la perdrix de savane, soit abrogée.Concernant la mouffette.Attendu que la mouffette est un prédateur qui cause beaucoup de dommage au cultivateur, en particulier dans les basses-cours; Attendu Qu'il y a lieu d'encourager, pour ces raisons, la chasse à ces prédateurs.Vu l'article 65 du chapitre 153 des Statuts refondus de Québec 1941.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre de la chasse et des pêcheries: Qu'il soit permis de chasser la mouffette à l'année dans toute la province, sujet toutefois aux lois et aux règlements de chasse en vigueur dans cette province.sier St., Montreal, district of Montreal, defendant.NOTICE An action for separation as to property has been instituted against the defendant on Julv 24 1957.Montreal, July 24, 1957.GRÉGOIRE DANSEREAU, DAOUST, VERNIER, DUCEPPE, DUGUAY & ALLAIRE, 45491 Petitioners for the Plaintiff.Order in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 729 Quebec, July 18, 1957.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning certain administrative agreements of the Department of Game and Fisheries.Concerning the hunting of Partridge.Whereas the Sharp-tailed Grouse is still scarce; Whereas the population of Birch and Spruce Partridge maintains a level that justifies a hunting season.Whereas that, for good administration, it has been deemed expedient to effectuate certain changes in the hunting season for Partridge.In view of section 65 of chapter 153 of the Revised Statutes of Quebec, 1941.It is consequently ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Game and Fisheries; That the hunting of Sharp-tailed Grouse be prohibited during 1957; That it be prohibited to hunt Birch and Spruce Partridge except from the last Saturday in September ot the fourth Sunday in November, these two days inclusively, under the following conditions: No one may kill or capture more than five (5) partridges a day; no one may have in his possession more than the legal three (3) days' catch; no one may have partridge in his possession after the sixth (6th) day of January, following the preceding hunting season.That the part of Order in Council number 695, dated July 4, 1956, concerning the Sharp-tailed Grouse and Birch and Spruce Partridge, be repealed.Concerning the Skunk.Whereas the Skunk is a depre dator that causes a great deal of damage to the armer, especially in poultry-yards; Whereas it is deemed expedient to encourage, for these reasons, the hunting of these depredators.In view of section 65 of chapter 153 of the Revised Statutes of Quebec, 1941.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Game and Fisheries : That it be permitted to hunt Skunk troughout the year in the whole of the Province subject, however, to the hunting laws and regulations in force in this Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol 89, No.31 2749 Concernant la chasse au faisan.Ayyendu Qu'il se poursuit des expériences pour l'acclimatation des faisans dans les comtés de Lotbinière et de Mégantic; Attendu Qu'il y a lieu de défendre la chasse au faisan pour 1957 afin de laisser une chance à l'espèce de se reproduire.Vu l'article 65 du chapitre 153 des Statuts refondus de Québec 1941.Il, est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre de la chasse et des pêcheries: Qu'il soit défendu de chasser et de tuer le faisan durant l'année 1957, dans les Comtés de Lotbinière et de Mégantic et que pour les années subséquentes la chasse au faisan soit faite suivant les prescriptions de la partie de l'arrêté en conseil N° 847, en date du 3 août 1955, concernant la chasse au faisan.Concernant le chevreuil et l'orignal.Attendu que le délai d'enregistrement d'un orignal ou d'un chevreuil tué dans la province est de nuit (8) jours après la mort de l'animal; Attendu Qu'il y aurait lieu de fixer ce délai à quarante-huit (48) heures après la sortie du cliasseur de la forêt.Vu l'article 65 du chapitre 153 des Statuts refondus de Québec, 1941.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre de la chasse et des pêcheries: 1° Que toute personne qui aura tué un chevreuil ou un orignal sera tenue d'en faire rapport à un garde-chasse; 2° Que ladite personne devra produire les cornes de tout orignal ou de tout chevreuil dans les zones où la femelle est protégée ou, simplement sur demande de l'officier qui procède à l'enregistrement; 3° Ces rapport et production de bois (cornes) devront se faire dans les quarante-huit (48) heures après la sortie du chasseur de la forêt; Que la partie de l'arrêté en conseil N° 448, en date du 28 avril 1949, concernant la chasse à l'orignal, au chevreuil et au caribou, ainsi que la partie de l'arrêté en conseil N° 777, en date du 28 juillet 1954, concernant l'orignal, le chevreuil et le caribour, soient abrogées.Concernant le chevreuil.Attendu que les conditions biologiques du chevreuil ont changé considérablement dans la province ces dernières années; _ Attendu Qu'il y a lieu de reviser les règlements afin d'accorder au chevreuil la protection qu'il faut pour maintenir la population à un niveau raisonnable; Vu l'article 65 du chapitre 153 des Statuts refondus de Québec 1941.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable minsitre de la chasse et des pêcheries: Qu'il soit défendu de chasser ou tuer le chevreuil dans la province, sauf dans les sections suivantes: 1° Dans la section sud de Montréal, connue aussi sous le nom de Zone A, exceptions faites des comtés de Vaudreuil-Soulanges; Du deuxième samedi de novembre au premier dimanche de décembre, pour le mAle seulement; 2° Dans la section sud-est de Québec, connue aussi sous le nom de Zone B; Du deuxième same- Concernino the hunting of Pheasant.Whereas experiments arc being carried out on the acclimatization of Pheasants in the counties of Lotbinière and in Megantic; Whereas it is deemed expedient to prohibit the hunting of Pheasant for 1957 in order to allow the species to breed.In view of section 65 of chapter 153 of the Revised Statutes of Quebec, 1941.It is ordained, upon the receommendation of the Honourable the Minister of Game and Fisheries: That it be prohibited to hunt, and to kill Pheasant during the year 1957, in the counties of Lotbinière and Megantic and that in subsequent years the hunting of Pheasant be done according to the prescriptions of Order in Council No.847, dated August 3, 1955, concerning the hunting of Pheasant.Concerning Deer and Moose.Whereas that the dealy in registering a Moose or Deer killed in the Province is eight (8) days after the death of the animal; Whereas it is deemed expedient to fix this delay at forty-eight (48) hours after the hunter has left the forest.In view of section 65 of chapter 153 of the Revised Statutes of Quebec, 1941.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Game and Fisheries: 1.That any person who has killed a deer or mosse shall report the fact to a game-warden; 2.That the said person shall produce the horns of any moose or of any deer within the zones where the female is protected or, simply upon the request of the officer in charge of the registration; 3.These reports, should be made, as well as the production of the horns, withint the forty-eight (48) hours after the hunter has left the forest; That the part of the Order in Council No.448, dated April 28, 1949, concerning the hunting of moose, deer and caribou, as well as the part of the Order in Council No.777, dated July 28, 1954, concerning moose, deer and caribou, be repealed.Concerning Deer.Whereas that the biological conditions of deer have considerably changed in the Province during these last years; Whereas that it is deemed advisable to revise the regulations in or order to grant deer the necessary protection to maintain the population at a reasonable level; In view of section 65 of chapter 153 of the Revised Statutes of Quebec, 1941.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Game and Fisheries: .That it be prohibited to hunt or kill deer in the Province, save in the following sections: 1.In the south section of Montreal, also known as Zone A, with the exception of the counties of Vaudreuil-Soulanges from the second Saturday in November to the first Sunday in December, for the male only; 2.In the southeast section of Quebec, also known under the name of Zone B: From the 2750 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S août 1967, Tome 89, N° 31 di de novembre au premier dimanche de décembre; 3° Dans la section des Laurentides et de Gaspé, connue aussi sous le nom de Zone C; Cu dernier samedi de septembre au quatrième dimanche de novembre; De plus, sur les territoires de la Réserve Hor-ton et du Club Tancrède, opérés par le gouvernement de la province, pour une saison additionnelle au tir à l'arc seulement; Durant les quatorze jours précédant le dernier samedi de septembre; 4° Dans la section ouest de la province, connue aussi sous le nom de Zone D: Du dernier samedi de septembre au troisième dimanche de novembre; 5° Dans l'Ile d'Anticosti; Du quinzième jour d'août d'une année au premier jour de février de l'année suivante.Que la partie de l'arrêté en conseil N°695, en date du 4 juillet 1950, concernant la chasse au chevreuil dans les comtés de Vaudruil-Soulanges; la partie de l'arrêté en conseil N° 844, en date du 3 août 1955, concernant la chasse au chevreuil; la partie de l'arrêté en conseil N° 777, en date du 28 juillet 1954, concernnrit la chasse au chevreuil sur l'île d'Anticosti; la partie de l'arrêté en conseil N° 847, en date du 3 août 1955, concernant la chasse au chevreuil la partie de l'arrêté en conseil N° 777, en date du 3 juin 1953, concernant la chasse au \u2022chevreuil; la partie de l'arrêté en conseil N° 1031, en date du 14septembre 1949, concernant un amendement à l'arrêté ministériel N° 448, en date du 28 avril 1949; la partie de l'arrêté en conseil N° 448, en date du 28 avril 1949, concernant la défense de chasser la femelle du chevreuil dans la Zone B, soient abrogées; Que l'arrêté en conseil N° 644, en date du 21 février 1946, soit amendé en conséquence.L.DÉSILETS.45484-0 Greffier du Conseil Exécutif.Avis divers second Saturday in November to the first Sunday in December; 3.In the section of the Laurentides and of Gaspé, also known under the name of Zone C: From the last Saturday in September to tlip fourth Sunday of November; Moreover, on the territories of the Horteu Reserve and of Tancrède Club, operated by the Government of the Province for an additional season for the bow and arrow only: During the fourteen days preceding the last Saturday of September; 4.In the west section of the Province, also known under the name of Zone D: From the last Saturday of September to the third Sunday of November; 5.On the Island of Anticosti : f rom the fifteenth day of August of a year to the first day of February of the following year.That the part of the Order in Council No.dated July 4, 1956, concerning the hunting of Deer in the counties of Vaudrcuil-SoulaiiL.~; that part of the Order in Council No.844, dated August 3, 1955, concerning the hunting of Deer; that part of the Order in Council No.777, dated July 28, 1954, concerning the hunting of Deer on the Island of Anticosti; that part of the On 1er in Council No.847, dated August 3, 1955, concerning the hunting of Deer; that part of the Order in Council No.777, dated June 3, 1953, concerning the hunting Deer; that part of the Order in Council No.1031, dated September II.1949, concerning an amendment to the Order in Council No.448, dated April 28, 1949; that part of the Order in Council No.448, dated April 28, 1949, concerning the defense of hunting the female of the deer in ZoneB, be repealed; That Order in Council No.644, dated February 21, 194h\\ be consequentlv amended.L.DÉSILETS.45484-0 Clerk of the Executive Council.Miscellaneous Notices AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE Avis est par les présentes donné que le conseil Public notice is hereby given that the Coun- de la municipalité du village de Maniwaki s'a- cil of the municipality of the village of Mnniwaki dressera au Lieutenant-Gouverneur en conseil, will apply to the Lieutenant Governor in Council pour demander l'érection du territoire de la mu- to request the erection of the territory of the nicipalité du village de Maniwaki en munici- municipality of the village of Mnniwaki as a pal ill'' de ville, sous l'empire de la Loi des Cités town under the Cities and Towns Act, under the et Villes, sous le nom de la municipalité de la name of the Municipality of the Town of Mam- ville de Maniwaki.waki.Ledit territoire, ayant une population de The said territory.having a population of 6,327 personnes, est borné comme suit: savoir: 6,327 persons, and being bounded as follows: Le territoire actuel de la municipalité du village The actual territory of the municipality of the de Maniwaki, comté de Gatineau, se composant village of Maniwaki, being composed of all the de tout le canton de Maniwaki et d'une partie Township of Maniwaki and part of the Township du canton de Egan, comprenant tous les lots of Egan, including all lots or parts of lot with ou parties de lot et leurs subdivisions présentes their present or future subdivisions, and also the et futures, aiflsi que les chemins, rues, ruelles, roads, streets, alleys, rivers, lakes, water-con.ses rivières, lacs, cours d'eau ou partie d'iceux ren- or part thereof contained in the following bounda-fermés dans les limites suivantes, à savoir: par- ries, to wit: starting at the summit of the south-tant du sommet de l'angle sud-ouest du canton west angle of the Township of Maniwaki; from de Maniwaki; de là, passant successivement, par there, passing successivaly, by the lines and deles lignes et démarcations suivantes: la ligne marcations following: the exterior west line of extérieure ouest du canton de Maniwaki pro- Township of Maniwaki prolongated to the axis longée jusqu'à l'axe ed larivière de l'Aigle; ledit of the Eagle River; the said axis of the Fagle axe de la rivière de l'Aigle en descendant son River descending its course and passing to the cours et contournant par la droite les îles les plus right the islands nearer to the left bank and rapprochées de la rive gauche et par la gauche les passing to the left of the islands nearer to the îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'à right bank to the axis of the Desert River: the l'axe de la rivière Désert; ledit axe de la rivière said axis of the Desert River descending its Désert en descendant son cours et contournant course and passing to the right of the islands QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 2751 rive gauche et par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement d'une ligne intersectant la rive gauche de la rivière a un point situé à une distance per-!>endiculaire de 435.6 pieds à l'est de la ligne separative des lots 4 et 5 rang A du canton d'Egan; ledit prolongement, puis en référence ji a cadastre officiel du canton d'Egan, ladite ligne, jusqu'à un point de la ligne separative des lots 1 et 5 rang A à une distance de 2975 pieds de la rive gauche de la rivière Désert mesurée le long de ladite ligne separative de lot; une ligne perpendiculaire à la ligne separative des lots 4 et 5 traversant le lot 5 jusqu'à la rive est du lac (Jilmore; ladite rive est du lac Gilmore en allant vers le nord jusqu'à sa deuxième intersection avec la ligne separative des lots 4 et 5 rang A; ladite ligne separative des lots 4 et 5 rang A en allant au nord ; la ligne séparant le rang A1 du rang II dans la direction de l'est jusqu'au côté nord-ouest de l'ancienne route no 11; ledit côté nord-ouest de l'ancienne route no 11 sur une distance de 1018 pieds; une perpendiculaire au dit côté nord-ouest de l'ancienne route no 11 en allant vers le sud-est jusqu'au côté ouest de la nouvelle route no 11; une perpendiculaire au dit côté ouest de la nouvelle route 11 traversant ladite route jusqu'à son côté est; ledit côté est de ladite route en allant vers le sud sur une distance approximative de 275 pieds jusqu'à la ligne nord du lot de subdivision 1-1 du rang I; cette dernière ligne et la ligne nord des lots de subdivision 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10; la ligne est du lot de subdivision 1-10 prolongée jusqu'à la ligne separative des rangs A et I; la ligne est du lot de subdivision 1-53 (une rue); la ligne separative des lots I et II rang A en allant vers le sud-est et son prolongement jusqu'à l'axe de la rivière Désert; ledit axe de la rivière Désert en descendant son cours jusqu'à l'axe de la rivière Gatineau; l'axe de la rivière Gatineau en descendant son cours et contournant par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement de la ligne extérieure sud du canton de Maniwaki et enfin ledit prolongement et ladite ligne extérieure sud du canton de Maniwaki jusqu'au point de départ; Donné à Maniwaki, ce huitième jour de juillet 1957.Le Procureur des pétitionnaires, 15378-28-4-0 MALCOLM MILLAR.P.Laporta Inc.Règlement N° 25 Qu'il soit décrété et il est par les présentes décrété comme un règlement de la compagnie que: 1° Attendu que la compagnie a cessé de faire all'aires; 2° Attendu que lu compagnie n'a plus aucune dette ni obligation; 3° En conséquence il est décrété que: a) La compagnie est par les présentes autorisée à disposer de ses actifs et à les répartir au prorata parmi ses actionnaires; b) Les directeurs et officiers sont par les présentes autorisés et requis de signer tous les documents et de poser tous les actes nécessaires pour l'exécution de ce qui précède.Décrété, ce dix-neuvième jour de juillet 1957.I émoin : Le Sceau de la compagnie.Certifié vraie copie Le Secrétaire, 45487-0 LINA LAPORTA.nearer the right bank to the prolongation of a line intersecting the left bank of the river at a point situated at a perpendicular distance of 435.6 feet to the east of the line dividing lots 4 and 5 range A of the Township of Egan; the said prolongation and, in reference of the Official Cadastre of the Township of Egan, the said line, to a point of the dividing line of lots 4 and 5 range A situated at a distance of 2975 feet from the left bank of the Desert River, measured along the said dividing line of lots 4 and 5; a line perpendi-dular to the dividing line of lots 4 ans 5 crossing lot 5 to the east bank of Lake Gilmore; the said east bank of lake Gilmore going towards the north to its second intersection with the line dividing lots 4 and 5 range A; the said line dividing lots 4 and 5 range A going towards the north; the line dividing range A from range II going towards the east to the north-west side of the old road no 11; the said north-west side of old road no 11 on a distance of 1018 feet; a perpendicular to the north-west side of old road no 11 going towards the south-east to the west side of the new road no 11 ; a perpendicular to the west side of the new road no 11 crossing the.said road to its east side; the said east side of the said road going towards the south for an approximate distance of 275 feet to the north line of subdivision lot 1-1 range I; the last said line and the north line of subdivision lots 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10; the east line of subdivision lot 1-10 prolongaged to the dividing line of range A and I; the east line of subdivision lot 1-53 (a street); the dividing line of lots I and II range A going towards the south-east and its prolongation to the axis of the Desert River; the said axis of the Desert River descending its course to the axis of the Gatineau River; the axis of the Gatineau River descending its course and passing to the right of the islands nearer the left bank and to the left of the islands nearer the right bank to the prolongation of the exterior south line of the Township of Maniwaki and finally the said prolongation and the said exterior south line of the Township of Maniwaki to the starting point.Given at Maniwaki, this eight day of July, 1957.MALCOLM MILLAR, 45378-28-4-o Attorney for the Petitioners.P.Laporta Inc.By-law No.25 Be it enacted and it is hereby enacted as bylaw No.25 of the company that : 1.Whereas the company has ceased to carry on business; 2.Whereas the company has no debt or obligation ; 3.Therefor be it enacted as a by-law of P.Laporta hie.that: a) The company be and is hereby authorized to dispose of its property, distribute its assets rateably amongst its shareholders; b) The directors and officers are hereby authorized and directed to do, sign and execute all things, deeds and documents necessary or desirable for the due carrying out of the foregoing.Enacted this nineteenth day of July, 1957.Witness: The Corporate Seal of the Company Certified true copy LINA LAPORTA, \u2022 45487-0 Secretary. 2752 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S août 1957, Tome 89, N° 31 Règlement Un règlement concernant la distribution de l'actif de la compagnie Sherbrooke City Transit Co.Ltd.1° Attendu que la compagnie a cessé d'exercer son commerce, sauf aux fins de ventilation de ses affaires; et 2° Attendu que la compagnie n'a pas de dettes ou obligations; En conséquence, qu'il soit décrété comme un règlement de la compagnie \"Sherbrooke City Transit Co.Ltd.\", que a) La compagnie soit et elle est, par les présentes, autorisée à disposer de ses biens, distribuer son actif au pro rata entre ses actionnaires et procéder subséquemment à sa dissolution par voie de procédures d'abandon de charte en-vertu de l'article 26 de la Loi des compagnies de Québec; 6) Les directeurs et officiers sont, par les présentes, autorisés et dirigés à faire, signer et exécuter toutes choses, actes et documents nécessaires ou opportuns à la bonne exécution du précédent.Décrété ce 19e jour de juillet 1957.Le Secrétaire-trésorier, 45488 PIERRE ST.PIERRE.\u2014 ; Extrait du règlement N° 4 de la compagnie \"Les Industries du Littoral Ltée \u2014 Littoral Industries Ltd.\".La compagnie est autorisée à disposer de ses biens, distribuer ses actifs proportionnellement à ses actionnaires et par après à prendre les procédures nécessaires pour demander l'abandon de sa charte suivant la section 26 de la Loi des Compagnies de Québec.Rivière Portneuf, ce 13 mai 1957.(Sceau) Le Secrétaire, 45486-o RAOUL TREMBLAY.(P.G.10275-56) Les Produits Laitiers Val Maska Inc.Val Maska Dairy Products Inc.Règlement N° 2 \"Il est statué par le Règlement N° 2: 1° Que le nombre des directeurs composant le bureau de direction de la compagnie \"Les Produits Laitiers Val Maska Inc.\", \"Val Maska Dairy Products Inc.\", soit augmenté de 3 à 4 directeurs; 2° Que 3 directeurs constituent le quorum à toute assemblée du bureau de direction; 3° Que le Règlement N° 1 de la compagnie, étant les règlements généraux, soit modifié en conséquence et que tous autres règlements, résolutions et décisions de la compagnie contraires au présent règlement sont par les présentes amendés, modifiés et revisés pour donner effet à ce règlement.\" Copie certifiée du Règlement N° 2 dûment adopté à une assemblée des directeurs de la compagnie tenue le 14e jour de mai 1957 et approuvé à une assemblée générale spéciale de la compagnie tenue le 14e jour de mai 1957 par tous les actionnaires de la compagnie détenant entre eux 100% du capital-actions de la compagnie.St-Damase, le 16 juillet 1957.(Sceau) Le Secrétaire, 45510-o LIONEL CORDEAU.By-law A by-law respecting the distribution of the assets of Sherbrooke City Transit Co.Ltd.1.Whereas the company has ceased to carry on business except for the purpose of winding up its affairs; and 2.Whereas the company has no debts or obligations; Now, therefore, be it enacted as a by-law of \"Sherbrooke City Transit Co.Ltd.\", that a) The company be and it is hereby authorized to dispose of its property, distribute its assets rateably amongst its shareholders and subsequently proceed to dissolution by way of surrender of charter under section 26 of the Quebec Companies' Act; b) The directors and officers are hereby authorized and directed to do, sign and execute all things, deeds and documents necessary or desirable for the due carrying out of the foregoing.Enacted this 19th day of Julv, 1957.PIERRE ST.PIERRE, 45488-o Secretary-Treasurer.Excerpt from by-law No.4 of the company \"Les Industries du Littoral Ltée \u2014 Littoral Industries Ltd.\".The company is authorized to dispose of its goods, proportionately distribute its assets among its shareholders and afterwards to take the necessary procedures to apply for the surrender of its charter according to section 26 of the Quebec Companies' Act.Rivière Portneuf, May 13, 1957.(Seal) RAOUL TREMBLAY, 45486 Secretary.(A.G.10275-56) Les Produits Laitiers Val Maska Inc.Val Maska Dairy Products Inc.By-law No.2 \"It is enacted by by-law No.2: 1.That the number of the Directors composing the Board of Directors of the company \"Les Produits Laitiers Val Maska Inc.\", \"Val Maska Dairy Products Inc.\", be increased from three to four Directors; 2.That 3 Directors constitute the quorum at any leeting of the Board of Directors; 3.That by-law No.1 of the company, being the general by-laws, be consequently modified and that all other by-laws, resolutions and decisions of the company contrary to the present by-law are by these presents amended, modified and revised to give effect to this by-law.\" Certified copy of By-law No.2 duly adopted at a meeting of the Directors of the company held on May 14th, 1957 and approved%t a special general meeting of the company held on the 14th day of May, 1957, by all the shareholders of the company holding amoungst themselves 100% of the capital stock of the company.St-Damase, July 16, 1957.(Seal) LIONEL CORDEAU, 45510 Secretary. (P.G.12264-57) La Compagnie du St-Louis Règlement N° 6 \"Qu'il soit et il est, par les présentes, décrété comme règlement numéro 6 des règlements de la Compagnie du St-Louis (ci-après appelée \"la compagnie\") ce qui suit, savoir: 1° Le nombre des directeurs de la compagnie est augmenté de six (6) à sept (7), et le bureau de direction de la compagnie se composera dorénavant de sept (7) membres.2° Quatre (4) directeurs constitueront un quorum à chaque assemblée du bureau de direction.3° Tous règlements et résolutions antérieurs inconciliables avec les présentes, sont amendés ou modifiés, de façon à donner pleinement effet au présent règlement.\" Décrété ce 4ième jour de juillet 1957.Certifié vraie copie Le Secrétaire, 45509-o JACQUES JUNEAU.(P.G.11074-57) Polytex Ltd.Un règlement qui augmente le nombre des directeurs de quatre à cinq Règlement N° XXIII \"Attendu qu'il est opportun de porter à cinq le nombre de directeurs: En conséquence qu'il soit décrété comme un règlement de cette compagnie, ce qui suit: Que le nombre des directeurs de cette compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté à cinq\" Certifié vraie copie du règlement N° XXIII décrété par les directeurs le 12e jour de juin 1957 et confirmé à l'unanimité par les actionnaires le 12e jour de juin 1957.Le Secrétaire, 45511 M.BRAININ.(P.G.11030-57) Avis est, par les présentes, donné que sur la recommandation de l'Assistant Procureur général, l'Honorable Secrétaire de la Province a, le 26 juillet 1957, approuvé les règlements numéros I à XVII inclusivement de \"The Dorval Recreation Association Lie\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 30e jour de juillet 1957._ Le Sous-secrétaire de la province.45512 JEAN BRUCHÉSI.(A.G.12264-57) La Compagnie du St-Louis By-Law No.6 \"That it be ami it is hereby decreed as by-law number 6 of the by-laws of the Compagnie du St.Louis (hereinafter called \"the company\") the following, to wit: 1.The number of the Directors of the company is increased from six (6) to seven (7), and the Board of Directors of the company shall hereinafter be composed of seven (7) members.2.Four (4) Directors shall constitute a quorum at each meeting of the Board of Directors.3.All by-laws and previous resolutions incompatible with the present ones, are amended or modified, so as to give full effect to the present by-law.\" Decreed this 4th day of Julv, 1957.Certified true copy JACQUES JUNEAU.45509 Secretary.(A.G.11074-57) Polytex Ltd.By-law to increase number of Directors from four to five By-Law No.XXIII \"Whereas it is expedient to increase the number of directors to five: Wherefore be it enacted as a By-Law of this Company as follows: That the number of Directors of this company be and the same is hereby increased to five directors.\" Certified to be a true copy of By-Law No.XXIII enacted by the directors on the 12th day of June, 1957 and unanimously confirmed by the shareholders on the 12th dav of June 1957.M.BRAININ, 45511 -o Secretary.(A.G.11030-57) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, By-lasw Nos.I to XVII inclusive of \"The Dorval Recreation Association Inc.\" have been approved on July 26th, 1957, by the Honourable the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary this 30th day of July 1957.JEAN BRUCHÉSI, 45512-0 Under-Secretary of the Province.Chartes \u2014 Abandon de Charters \u2014 Surrender of Sherbrooke City Transit Co.Ltd.Sherbrooke City Transit Co.Ltd.Avis est donné par les présentes que Sherbrooke Notice is hereby given that Sherbrooke City City Transit Co.Ltd., une compagnie incorporée Transit Co.Ltd.; incorporated under the Quebec sous le Loi des Compagnies de Québec, a Pin- Companies'Act, intends to apply to the Attorney tention de demander au Procureur Général de General of the Province of Quebec for leave to la Province de Québec la permission d'abandonner surrender its charter, sa charte.Montréal, le 19 juillet, 1957.Montreal, July 19th, 1957.Sherbrooke City Transit Co.Ltd.Sherbrooke City Transit Co.Ltd., Le Secrétaire-trésorier, PIERRE St.PIERRE, 45488-0 PIERRE St.PIERRE.45488-0 Secretary-Treasurer. Prenez avis que la Cie de Développement de Weed on, Weed on Development Co., demandera au Procureur Général la permission d'abandonner sa charte.Sherbrooke, 30 juillet 1957.Les Procureurs de la Compagnie, DESRUISSEAUX, FORTIN 45489-0 & ROUILLARD.Deux Montagnes Excavation Limitée Avis public est donné conformément à la Loi des Compagnies de Québec que la compagnie \"Deux-Montagnes Excavation Limitée\" demandera la permission d'abandonner sa charte.Lachute, ce 25 juillet 1957.L'Avocat de la Requérante, 45492-0 ROGER LAGARDE.Albert Rousseau Limitée Avis est par les présentes donné que Albert Rousseau Limitée, compagnie constituée en vertu de la Loi des Compagnies de Québec, ayant son siège social dans la cité de Montréal, demandera au procureur général de la Province de Québec la permission d'abandonner sa charte.Montréal, ce 23 juillet 1957.Le Secrétaire, 45513-o (S) F.ROUSSEAU.Take notice that the Cie de Développement de Weedon, Weedon Development Co., will apply to the Attorney General for permission to surrender its charter.Sherbrooke, July 30, 1957.DESRÙISSEAUX, FORTIN & ROUILLARD, 45489 Attorneys for the Company.Deux Montagnes Excavation Limiték Public notice is given according to the Quebec Companies' Act that \"Deux-Montagnes Excavation Limitée\" will ask the permission to surrender its charter.Lachute, July 25th 1957.ROGER LAGARDE, 45492-o Attorney for petitioner.Albert Rousseau Limitée Notice is hereby given that Albert Rousseau Limitée, a company incorporated under the Quebec Companies' Act, having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for permission to surrender its charter.Montreal, July 23, 1957.(S) F.ROUSSEAU, 45513 Secretary.Hibbard Motors Ltd.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie Hibbard Motors Ltd., une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Cowansville, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Cowansville, 19 juillet 1957.Le Président, Mme ETHEL EVA HIBBARD.Les Procureurs de la requérante, Mendelsolm, Rosentzveig & Shacter, 132 ouest, rue St-Jacques, Montréal, Québec.45514 Curatelle publique Hibbard Motors Ltd.Notice is hereby given that Hibbard Motors Ltd.a corporation constitued under the Quebec Companies Act and having its head office in the City of Cowansville, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its Charter under the provisions of the Quebec Companies Act.Dated at Cowansville, July 19th, 1957.Mrs.ETHEL EVA HIBBARD, President.Mendelsohn, Rosentzveig & Shacter, 132 St.James St.West, Montreal, Quebec.Attorneys for Applicant.45514-0 Public Curatorship Canada \u2014 Province de Québec District de Québec Succession vacante de Isidore Gratton, en son vivant de Pont Viau, Québec.Le soussigné donne avis que cette succession a été déclarée vacante en vertu d'un jugement rendu le 3 mai 1956 par un juge de la Cour supérieure siégeant à Montréal dans le district de Montréal que, sous l'autorité de la loi de la curatelle publique (9 Geo.VI, c.62), il est curateur d'office à cette successsion, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.LE CURATEUR PUBLIC, 187, rue Sainte-Catherine (Ouest), 45503-o Montréal 18.Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal Vacant estate of Isidore Gratton in his lifetime of Pont Viau, Quebec, The undersigned gives notice that the said estate has been declared vacant in virtue of a judgment rendered on May 3, 1956, by a judge of the Superior Court sitting at Montreal, in the district of Montreal, that he is, under the authority of the Public Curatorship Act (9 Geo.VI ch.62), curator ex-officio to the said estate, and that he will receive, at the address given below, the payment of all debts owing to the said estate and proof of all claims against it.THE PUBLIC CURATOR, 187, Saint-Catherine St.(West), 45503 Montreal, 18. QUEBEC Off ICI AL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol 89, No.31 2755 Demande à la Législature Province de Québec Comte de Drummond Avis public est par les présentes donné que Claude Rocheleau, sergent de police de la Sûreté Provinciale, de Drummondville, s'adressera à la Législature de Québec, à sa prochaine session, pour l'adoption d'une loi aux fins d'autoriser les légataires fiduciaires nommés par le testament de feue Dame Julie Lalanne, veuve de Antoine Ro-cheleau, à lui remettre sa part d'héritage sans attendre qu'il ait atteint l'âge de 35 ans, tel que mentionné au testament.» L'avocat du requérant, 45457-30-4-o PAUL ROUSSEAU, C.R.Département de l'Instruction Publique Application to Legislature Province of Quebec County of Drummond Public notice is hereby given by these presents that Claude Rocheleau, Police Sergeant for the Provincial Police Force of Drummondville, will apply to the Quebec Legislature at its next session, for the adoption of an Act for the purposes of authorizing the fiduciary legatees named in the will fo the late Dame Julie Lalanne, widow of Antoine Rocheleau, to remit to him his share of the inheritance without waiting until he reaches the age of 35, as mentioned in the testament.PAUL ROUSSEAU, Q.C., 45457-30-4 Advocate of the Petitioner.Department of Education N° 495-57.Québec, le 23 juillet 1957.11 a plu au Lieutenant-gouverneur en Conseil, par arrêté ministériel en date du 10 juillet 1957, de détacher de la municipalité scolaire de Sacré-Cœur-de-Jésus paroisse, dans le comté de Stans-tead, les lots 569 et 570 du rang VII du cadastre officiel du canton de Stanstead, pour les annexer, pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire catholique de Beebe-Plain, dans le même comté.Ce changement prendra effet au 1er juillet 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, ' 45494-0 O.J.DÊSAULNIERS.N° 324-55.Québec, le 23 juillet 1957.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire du village de Ste-Rosalie, dans le comté de Bagot, le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer à la municipalité scolaire de la Cité de St-Hyacinthe, dans le comté de St-Hya-cinthe.Un certain territoire faisant partie du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Rosalie, dans le comté de Bagot, renfermé dans les limites suivantes, savoir: Commençant au point \"A\" du plan préparé par l'arpenteur-géomètre Grégoire Girard, le 8 mai 1957, lequel point indique l'intersection de la ligne sud-est du chemin public en front du rang LI de la paroisse de Ste-Rosalie, avec la ligne de division entre les lots 130 et 131; du point \"A\" suivant la ligne de division entre les lots 130 et 131 vers le sud-est jusqu'au point \"R\"; de là vers le sud-ouest suivant le cours d'eau \"Donat Girard N° 8948\" en traversant les lots 131, 132, 133, 135 et 136 jusqu'au point \"C\"; de là vers le sud-est suivant la ligne de division entre les lots 136 et 137 jusqu'au point \"D\"; de là vers le sud-ouest suivant la ligne nord-ouest du Boulevard Sir Wilfrid Laurier jusqu'au point \"E\"; de là vers le nord-ouest suivant la ligne de division entre le lot 143A -16et une partie non subdivisée du lot 143A jusqu'au point \"F\"; de là vers le sud-ouest suivant la ligne de division entre le lot 143A-15 et le lot 143A-16 jusqu'au point \"G\"; de là vers le nord ouest suivant la ligne de division entre les lots 143A-15, 143A-61, 143A-24, 143A-63 d'une part, 143A-18, 143A-19, 143A-60, 143A-22, 143A-23, 143A-62 d'autre part jusqu'au No.495-57.Quebec, July 23, 1957.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated July 10, 1957, to detach from tile School municipality of Sacré-Cœur-de-Jésus parish in the county of Stanstead, lots 569 and 570 of range VII of the official cadaster of the township of Stanstead, to annex them, for the Catholic ratepayers only, to the Catholic School municipality of Beebe-Plain, in the same county.This change will be come effective on July 1st, 1958.O.J.DÊSAULNIERS, 45494 Superintendent of Education.No.324-55.Quebec, July 23, 1957.Application is made to detach from the school municipality of the village of Ste-Rosalie, in the county of Bagot, the territory hereinunder described to annex it to the school municipality of the city of St-Hyacinthe, in the county of St.Hyacinthe.A certain territory forming part of the official cadastre of the parish of Ste-Rosalie, in the county of Bagot, enclosed within the following limits, to wit: Starting at point \"A\" of the prepared plan by the surveyor Grégoire Girard, on May 8, 1957, which point indicates the intersection of the southeast line of the public road in front of range II of the parish of Ste-Rosalie, with the dividing line between lots 130 and 131; from point \"A\" following the dividing line between lots 130 and 131 on the southeast to the point \"B\"; thence on the southwest following the watercourse \"Donat Girard No.8948\" crossing lots 131, 132, 133, 135 and 136 as far as point \"C\"; thence, on the southeast following the dividing line between lots 136 and 137 as far as point \"D\"; thence on the southwest following the northwest line of the Sir Wilfrid Laurier Boulevard as far as point \"E\"; thence on the northwest following the dividing line between lot 143A-16 and an undivided part of lot 143A as far a point \"F\"; thence, on the southwest following the dividing line between lot 143A-15 and lot 143A-16 as far as point \"G\"; thence on the northwest following the dividing line between lots 143A-15, 143A-16,143A-24, 143A-63 on one part, 143A-18, 143A-19, 143A-60, 143A-22, 143A-23, 143A-62 point \"H\"; de là vers le nord suivant la ligne de division entre les lots 143A-64, 143A-67, 143A-70, 143A-75, 143A-77, 143A-80, 143A-84.142-96, 142-100, 143-103, 142-110, 142-111, 142-112 d'une part, 143A-62, 143A-63, 143A-66, 143A-71 à 143A-74 inclusivement, 143A-78, 143A-81 à 143A-83 inclusivement, 142-97 à 142-99 inclusivement, 142-104 à 142-109 inclusivement d'autre part jusqu'au point \"I\"; de là vers le sud-ouest suivant la ligne de division entre le lot 142-109 et le lot 142-92 jusqu'au point \"J\"; de là vers le nord suivant la ligne est du chemin public jusqu'au point \"K\"; de là vers le nord-est suivant la ligne sud-est du chemin public jusqu'au point \"A\", point de départ.Le Surintendant de l'Instruction publique, 45495-3 f-2-o O.J.DÊSAULNIERS.N° 241-57.Québec, le 24 juillet 1957.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Ste-Jeanne-de-Neuville, dans le comté de Portneuf, en celui de \"La municipalité scolaire de Sîe-Jeanne-de-Pont-Rouge, dans le comté de Portneuf\".Le Surintendant de l'Instruction publique, 45490-31-2-o O.J.DÊSAULNIERS.Département des Mines Province de Québec Ministère des Mines Avis de rénovation des droits de mine Conformément aux articles 50, 51, 51A et suivants de la Loi des Mines de Québec (S.R.Q., 1941, chap.196) tels qu'amendés par 3-4 Elisabeth II, chap.38, avis est présentement donné aux détenteurs des droits de mine sur les terrains ci-dessous mentionnés qu'après un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent avis, le Ministre des Mines recommandera au Lieutenant-gouverneur en conseil la révocation quant aux droits de mine de ces terrains, si l'exploitation d'iceux est demeurée inactive pen-dans les vingt et une année qui ont suivi le 1er mars 1934, à savoir: Dans le canton de Ham Nord Rang III, lots 18A, 18B, 19A, 19B, 20A, 20B, 20C, 21A, 21B.21C.Québec, le 4 juillet 1957.Le Sous-minsitre, 45458-30-2-o A.O.DUFRESNE.Départements des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel du canton de Ditchfield, (municipalité de Ville de Mégantic), division d'enregistrement de Frontenac.Avis est par la présente donné que le lot 1-144 du Rang I, village Agnès est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 9 juillet 1957.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 45485-o A VILA BÉDARD.on the second part to the point \"II\"; thence on the north following the dividing line between lots 143A-64, 143A-67, 143A-70, 143A-75, 143A-77, 143A-80, 143A-84, 142-96, 142-100, 143-103 142-110, 142-111, 142-112 on one part, 143A-G2 143A-63, 143A-66, 143A-71 to 143A-74 inclu-sively, 143A-78, 143A-81 to 143A-84 inclusively 142-97 to 142-99 inclusively, 142-104 to 1-12-109 inclusively on the other part as far as point \"I\"; thence on the southwest following the dividing line between lot 142-109 and lot 142-92 as far as point \"J\"; thence on the north following the cist line of the public road as far as point \"K\"; thence on the northeast following the southeast line of the public road as far as the point \"A\", starting point.O.J.DÊSAULNIERS, 45495-31-2 Superintendent of Education.No.241-57.Quebec, July 24, I9Ô7.Application is made to change the name of the school municipality of Ste-Jcanne-de-Ncuville, in the county of Portneuf, into that of \"The School Municipality of Ste-Jeanne-de-Pont-Kongo, in the count v of Portneuf\".O.J.DÊSAULNIERS, 45496-31-2 Superintendent of Education.Department of Mines Province of Quebec Department op Mines Notice of revocation of mining rights Pursuant to sections 50, 51, 51A and following of the Quebec Mining Act (R.S.Q.1941, chap.196) as amended by 3-4 Elizabeth II, chap.38, notice is hereby given to the holders of mining rights on the parcels of land here under listed that after a delay of ninety days from the date of the present notice, the Minister of Mines will recommend to the Lieutenant-governor in Council the revocation of the mining rights on these concessions of land, the working of which has remained inactive during the twenty-one years following the first of March 1934, to wit: In North Ham Towsnhip Range III, lots 18A, 18B, 19A, 19B, 20A, 2013, 20C, 21A, 21B, 21C.Quebec, July 4th, 1957.A.O.DUFRESNE, 45458-30-2-o Deputy Minister.Department of Lands and Forests NOTICE Official cadastre of the township of Ditchfield.(municipality of town of Mégantic), registration division of Frontenac.Notice is hereby given that lot 1-144, Range I.village of Agnès has been added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, July 9, 1957.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, A VILA BÉDARD, 45485-o Deputy Minister. Cadastre officiel du canton Labarre, (munie!- Officiai cadastre of the township of Labarre, palité de village de St-Bruno), division d'enre- (municipality of village of St-Bruno), registra- gistrement de Lac St-Jean-Est.tion division of Lac St-Jean-Est.Avis est par la présente donné que le lot ll-F-2 Notice is hereby given that lot 1 l-F-2 and part et une partie du lot 11 -F-l du Rang V sont remis of lot ll-F-1, Range V are revised and lots en vigueur et que les lots ll-F-1 et ll-F-2 du ll-F-1 and ll-F-2, Rang V are corrected in Rang V sont corrigés en vertu de l'article 2174A Article 2174A of the Civil Codé, du Code civil.Québec, le 9 juillet 1957.Quebec, July 9, 1957.Le Département des Terres et Forêts, Department of Lands and-Forests, Service du Cadastre, Cadastral Branch, \" Le Sous-ministre, AVILA BÉDARD, 454S5-0 AVILA BÉDARD.45485-o Deputy Minister.Cadastre officiel de la paroisse de St-Antoine de Officiai cadastre of the parish of St.Antoine de Longueuil, (municipalité de cité de Jacques- Longueuil, (municipality of city of Jacques-Cartier), division d'enregistrement de Cham- Cartier), registration division of Chambly.bly.\u2014 Avis est par la présente donné que les lots\" Notice is hereby given that lots 133-818 to 133-818 à 133-820, 144-594 à 144-596, 145-594 133-820, 144-594 to 144-596, 145-594 to 145-596, à 145-596, 144-821 à 144-827 sont annulés en 144-821 to 144-827 are cancelled, in virtue of vertu de l'article 2174A du Code civil.Article 2174A of the Civil Code.Québec, le 16 juillet 1957.Québec, July 16, 1957.Le Département des Terres et Forêts, Department of Lands and Forests, Service du Cadastre, Cadastral Branch, Le Sous-ministre, AVILA BÉDARD, 45485-0 AVILA BÉDARD.45485-0 Deputy Minister.Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Flore, municipalité de Shawinigan-Est, division d'enregistrement des Trois-Rivières.Avis est par les présentes donné que les lots 35-12 à 35-29 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 10 juillet 1957.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 454S5-0 AVILA BÉDARD.Cadastre officiel de la paroisse de St-Jean, divison d'enregistrement de L'Ile D'Orléans.Avis est par la présente donné que les lots 7, 8, 9,10, 11 et partie des lots 2 et 6 sont annulés et (pie le lot 309 est ajouté en vertu de l'article 217IA du Code civil.Québec, le 19 juillet 1957.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 45485-0 AVILA BÉDARD.Cadastre officiel de la paroisse de St-Laurent, municipalité de la cité de St-Laurent, division d'enregistrement de Montréal._ Avis est par la présente donné que' les lots 345-326 à 345-328 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 8 juillet 1957.Le Département des Terres, et Forêts, Service du Canastre, Le Sous-ministre, 45485-0 AVILA BÉDARD.Officiai cadastre of the parish of Ste.Flore, municipality of Shawinigan-East, registration division of Three-Rivers.Notice is hereby given that lots 35-12 to 35-29 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code., Quebec, July the 10th, 1957.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD.45485-0 Deputy Minister.Official cadastre of the parish of St-Jean, registration division of Ile D'Orléans.Notice is hereby given that lots 7, 8, 9, 10, 11 and part of lots 2 and 6 are cancelled and lot 309 has been added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, July 19, 1957.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 45485-0 Deputy Minister.Official cadastre of the parish of St.Laurent, municipality of the city of St.Laurent, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 345-326 to 345-328 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, July the 8th, 1957.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 45485-0 Deputy Minister. 2758 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S août 1957, Tome 89, N° SI Département du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 103 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie et.aux métiers de la construction dans la région de Montréal, rendue obligatoire par le décret numéro 314 du 27 mars 1957, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil les modifications suivantes audit décret: L'article 30 sera remplacé par le suivant: \"Article 80: Jours de fête: Tous les salariés qui travaillent le Premier jour de l'An, le Vendredi-Saint, la Saint-Jean-Baptiste, le jour de la Confédération (1er juiHet), la fête du Travail, le jour d'Actions-de-Graces, Noël et le dimanche doivent être rémunérés au taux de salaire double, excepté : a) Ceux qui complètent une journée régulière de travail ou une période de travail commencée la journée précédente, pas plus tard que 8.00 p.m., laquelle se continue en partie durant le dit jour de fête ou le dimanche.\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoire ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-Ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 3 août 1957.45483-0 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la Convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), qu'il se propose de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil la modification suivante à la section \"D\" (Dispositions spéciales concernant le métier de plâtrier) du décret numéro 314 du 27 mars 1957, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal: L'article VII (Matériaux et pose) de ladite section \"D\" sera biffé.La publication du présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 3 août 1957.45483-o Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the construction industry and trades in the region of Montreal, rendered obligatory the decree No.314 of March 27, 1957, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendment to the said decree: Article 30 will be replaced by the following: \"Article 30: Holidays: All employees wdio work on New Year's Day, Good Friday, St.Jean Bap.liste Day, Confederation Day .(July 1), Labour Day, Thanksgiving Day, Christmas Day and Sundays shall be paid at the rate of double time, except : a) Those completing a regular work day or a shift which was started not later than 8.00 p.m.; on the previous day and extends in part into one of the said holidays or Sundays;\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Ordcr-in-Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy-Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 3, 1957.45483-0 NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that he intends to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendment to part \"D\" (Special provisions concerning the plastering trade) of the decree No.314 of March 27, 1957, relating to the construction industry and trades in the region of Montreal: Article VII (Materials and laying) of the said part \"D\" will be deleted.The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order-in-Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 3, 1957.454S3-0 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 2759 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans les comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes, Terre-bonne et Laval, rendue obligatoire par le décret numéro 140 du 27 février 1952 et amendements, lui ont présenté une requête à l'effet d'étendre la juridiction territoriale dudit décret au comté de Labelle, en y apportant les modifications suivantes: 1° L'article II sera remplacé par le suivant: \"H.Juridiction territoriales: La juridiction territoriale du présent décret comprend les districts électoraux d'Argenteuil, Papineau, Deux-Montagnes, Terrebonne, l'Ile Jésus'ainsi que les villes et municipalités suivantes du district éjcctoral de Labelle : Mont-Laurier, Lac-des-Kcorces, Labelle, l'Annonciation et Val-Barrette et le territoire compris dans un rayon de trois (3) milles de leurs limites.Aux fins d'application, cette juridiction est divisée en deux (2) zones comme suit: Zone I: Les cites et villes de toute la juridiction territoriale avec un rayon de trois (3) milles de leurs limites ainsi que les municipalités de Orownsburg, Saint-Jovite et Sainte-Adèle.Zone II: Toute la juridiction territoriale a l'exception du territoire compris dans la zone I.\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seuls un arrêté ministériel peut rendre obligatoire ces dispositons, avec ou sans amendements.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objection que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-Ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 3 août 1957.45483-0 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la Convention collective-de Travail, qu'il se propose de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil des modifications aux taux de salaires de la section \"E\" (relative aux métiers d'électricien) du décret N° 1121 du 10 octobre 1955 de façon qu'elle se lise comme suit et soit insérée dans le nouveau décret N° 314 du 27 mars 1957, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal: Section \"E\" Dispositions spéciales concernant le métier d'électricien I.Juridiction porfessionnelle: La présente section s'applique à tout travail de construction exécuté et soumis à la Loi concernant les élec- NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the Barbor and Hairdresser Trades in the counties of Argenteuil, Deux-Montagnes, Terrebonne and Laval, rendered obligatory by the decree number 140 of February 27th, 1952, and amendments, have petitioned him to extend the territorial jurisdiction of the said decree to the county of Labelle through the following amendments: 10 Section II will be replaced by the following: \"II.Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction of the present decree comprises the electoral districts of Argenteuil, Papineau, Deux-Montagnes, Terrebonne, Jesus Island and the following towns and municipalities of the electoral district of Labelle: Mont-Laurier, Lac-des-Écorces, Labelle, L'Annonciation and Val-Bar-rette and the territory comprises in a radius of three (3) miles from their limits.For the purposes of enforcement, this jurisdiction is divided into two (2) zones as follows: Zone I: The cities and towns of the entire territorial jurisdiction with a radius of three (3) miles from their limits, including the municipalities of Brownsburg, Saint Jovite and Sainte Adèle.Zone II: The entire territorial jurisdiction with the exception of the territory comprises in zone I.\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments can only be rendered obligatory by an Order-in-Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy-Minister of Labour.Deaprtment of Labour, Quebec, August 3, 1957.45483-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, that lie intends to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the wage rates of Part \"E\" (concerning the electrical trade) of the decree No.1121 of October 19, 1955, so that the said Part \"E\" will read as follows and be inserted in the new decree No.314 of March 27, 1957, relating to the construction industry and trades in the region of Montreal : Part \"E\" Special provisions concerning the electrical trade I.Professional Jurisdiction: The present part applies to and is effective in all work executed and governed by the Electricians and Electrical triciens et les installations électriques, \"Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 172 et amendements).Cependant, la présente section ne s'applique pas aux mécaniciens de brûleurs à l'huile régis par le chapitre premier du présent décret.II.Taux minima de salaires: Les taux minima de salaires sont les suivants: par heure Entrepreneur maître-électricien A compter travaillant comme salarié et du 1er mars détenteur de la licence \"A\", 1958 qu'il utilise ses outils ou agisse comme contremaître ou remplisse toute autre fonction de surveillance.S2.85 $2.95 Le détenteur de la licence \"B\", qu'il utilise ses outils ou agisse comme contremaître ou remplisse toute autre fonction de surveillance.2.85 2.95 Compagnon électricien, détenteur de la licence \"C\".2.10 2.20 Apprentis: Les taux de salaires payables aux apprentis sont fixés suivant le pourcentage du salaire minimum légal payé au compagnon électricien; ce pourcentage de rémunération est le suivant: 1 ère année.40% 2ième année.50% 3ième année.60% 4ième année.75% Tout électricien ou contremaître ayant 5 compagnons électriciens et 5 apprentis ou plus, sous sa direction, lorsqu'il s'agit de travaux de construction ou de modernisation, doit bénéficier d'une majoration dé 80.25 pour chaque heure de travail.III.Durée régulière du travail: La durée régulière de travail pour les compagnons et les apprentis électriciens est de huit (8) heures par jour, distribuées entre 8.00 a.m.et 5.00 p.m.les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, le tout devant constituer une durée hebdomadaire de quarante (40) heures.IV.Travail supplémentaire: 1° Tout travail exécuté en plus des heures régulières ou en dehors des limites horaires déterminées au paragraphe précédent est considéré comme du travail supplémentaire.2° Tout travail supplémentaire, à l'exclusion des dispositions prévues aux sous-paragraphes suivants, doit être rémunéré au taux de salaire et demi par rapport au taux de salaire minimum établi à l'article II ou par rapport au taux de salaire effectivement payé, lorsque ce dernier est plus élevé.3° Tout travail exécuté entre 10.00 p.m.et 8.00 a.m., les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et après 1.00 p.m.le samedi, doit être rémunéré au taux de salaire double par rapport au taux de salaire minimum établi à l'article II ou par rapport au taux de salaire effectivement payé lorsque ce dernier est plus élevé.4° Équipes irrègulières: Un supplément de S0.10 l'heure doit être versé aux salariés appelés à exécuter leur travail quotidien en deux étapes séparées par plus d'une heure (broken shift).Par dérogation aux taux édictés pour les heures supplémentaires aux alinéas précédents, les cinq premières heures du temps supplémentaire doivent être rémunérése au taux de salaire et demi, les heures suivantes au taux de salaire double, basé sur le taux régulier ou sur le salaire effectivement payé lorsque ce dernier est plus élevé.5° Tout travail urgent d'altération ou derépara-t.ion àun immeuble qui, pourdes raisons suffisantes, Installations Act (B.S.Q., 1941 chapter 172 and amendments).However, the present part does not apply to oil-burner-mechanics governed by the First Chapter of the present decree: II.Schedule of wage rates: The following minimum wage rates shall be payable: per hour Contracting M aster Electrician from working as an employee and March /, holding license \"A\", whether 1958 be uses his tools or acts as foreman or fulfils any other supervisory functions.$2.85 $2.95 Holder of license \"B\", whether he uses his tools or acts as foreman or fulfils any other supervisory functions.2.85 2.95 Electrician journeyman holding license \"C\".2.10 2.20 Apprentice: Rates of wages paid to apprentices shall be fixed according to the following percentage of legal minimum wages paid to electrician journeymen: 1st year.\u202210% 2nd year.50% 3rd year.60% 4th year.r.75% Every electrician or foreman in charge of five electrician journeymen and five apprentices or more shall be entitled to a surplus of 80.25 per hour for each working hour for construction or modernization work.III.Regular duration of labour: Regidar duration of labour for electrician journeymen and apprentices shall be eight (8) hours per clay between 8.00 a.m.and 5.00 p.m.on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays, making a maximum of forty (40) hours per week : IV.Overtime: 1.All time worked in excess of the regular hours or beyond the hours mentioned in the foregoing subsection is considered as overtime.2.All overtime, except for the provisions of the following paragraphs, shall be paid at the rate of time and one half based on the minimum wage rate established in article II, or on the wage rate actually paid if the latter be higher.3.All time worked between 10.00 p.m.and 8.00 a.m.on Monday, Tuesday, Wednesday.Thursday and Friday, and after 1.00 p.m.on Saturday, shall be paid at the rate of double time based on the minimum wage rate established in article II, or on the wage rate actually paid if the latter be higher.4.Broken shifts: A premium of $0.10 per hour shall be paid to employees working on any day shift broken by more than on hour.Notwithstanding the rates established for overtime in the foregoing paragraphs, the first five hours of overtime shall be paid at the rate of time and one half and the following hours at the rate of double time based on the regular rate, or on the rate actually paid if the latter be higher.5.All urgent building alteration or repair work which, for sufficient^ reasons, cannot be J QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1.957, Vol.S9, No, 81 2761 ne peut être execute en deçà des limites horaires déterminées ci-haut pour le commencement et la cessation du travail, peut être fait en d'autres périodes de la journée, aux taux réguliers.Toutefois, ledit travail supplémentaire demeure toujours sujet à la limite do huit (S) heures par jour cl de cpiarante (40) heures par semaine.Tous les salariés affectés à un tel travail doivent recevoir un supplément de $0.05 sur les taux réguliers.V.Travail en dehors des limites de Montréal: Les limites de Montréal, pour les fins de la présente section, sont les points extrêmes où l'on peut se rendre avec un billet ordinaire de tramway ou d'autobus de la Commission de Transport de Montréal.Les salariés travaillant en dehors des limites de la cité, doivent se rendre sur le chantier et le quitter aux heures régulières.- Le temps requis pour se rendre des limites de la ville au chantier et pour revenir aux limites, doit leur être payé au taux simple ainsi que le prix du transport pour ledit trajet.Dans le cas de travaux exécutés en dehors des limites de la cité, on peut varier les heures de commencement et de cessation du travail en vue de les adapter aux heures de services de transport publié, pourvu que ne s'ensuive pas une semaine de travail de plus de quarante (40) heures.Les frais de pension et de transport doivent être payés par l'employeur lorsqu'il s'agit de travaux en dehors des limites de Montréal.VI.Apprentis: 1° Aucun employeur n'a le droit d'avoir plus d'un (1) apprenti pour chaque compagnon électricien à son emploi, tel que spécifié à l'article 22 de la Ix>i concernant les Électriciens et les Installations Électriques, (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 172 et amendements).2° Toutefois, sur chaque chantier, l'employeur a droit à un apprenti additionnel de quatrième année pour chaque cinq (5) compagnons électriciens à son emploi.3° Pour pratiquer le métier d'électricien, l'apprenti doit avoir un certificat d'apprenti émis par les autorités provinciales, en vertu des dispositions du chapitré 172 des Statuts refondus de Québec 1941 et amendements.VIL Vacances payées: Le titre cinquième du présent décret se rapportant aux vacances payées s'applique à la présente section, mais il est entendu que tout employeur doit apposer à l'échéance de chaque paie de son salaire, dans le livret de congé de ce dernier, des timbres pour une valeur égale à quatre pourcent (4%) du montant brut de telle paie.Note: Les conditions générales de travail prévues dans le décret principal demeurent en vigueur sauf s'il en est disposé autrement dans la présente section.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoire ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 3 août 1957.45483-o done within the limits of hours hereabove determined for starting and finishing, may be done in other periods of the day, at regular rates.However, such overtime work is always subject to the 8-hour daily limit and the 40-hour weekly limit.All employees engaged in such work shall receive a premium of 80.05 over the regular rates.\": V.Operations outside the limits of Montreal: The limits of Montreal, for the purpose of this part, shall be those extreme places that can be reached with an ordinary streetcar or bus fare of the Montreal Transportation Commission.Employees working outside the city limits shall get to and leave the job at the regular hours.The time required to go from the city limits to the' job, and back to the limits, shall be paid straight time; the cost of such transportation shall also be paid by the employer.For operations carried out outside the city limits, if is permissible to change the starting and finishing time in order to adapt same to the time of leaving and returning of the public transportation providing the change does not entail the working of more than forty (10) hours in one week.Board and travelling expenses shall be paid by the employer in the case of operations carried out outside the limits of Montreal.VI.Apprentices: 1.No employer shall have the right to employ more than one (1) apprentice for each electrician journeyman working for him as provided by section 22 of the Electricians and Electrical Installations Act, (R.S.Q., 1941, chapter 172 and amendments).2.However, the employer shall have the right to employ on each job one additional 4th year apprentice to each five (5) journeymen in his employ.3.To become an electrician journeyman, the apprentice shall obtain a certificate of apprenticeship issued by the Provincial Government under the Electricians and Electrical Installations Act, (R.S.Q., 1941, chapter 172 and amendments).VII.Vacation with pay: The Fifth Title of the present decree concerning vacations with pay apply to the present part, but employers shall, at the end of each pay period, affix stamps in their employee's stamp book in an amount equivalent to four per cent (4%) of the gross amount of such pay.Note: The general working conditions contained in the decree continue to apply except in cases covered by the present part.\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained thereto.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order-in-Council Which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of^this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties mav wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 3, 1957.45483-0 2762 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, $ août 1957, Tome 89, N° 81 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la fourrure, section du détail, région de Montréal, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil les modifications suivantes au décret numéro 643 du 20 mai 1953: 1° Le paragraphe \"a\" de l'article II sera remplacé par le suivant: \"IL Juridiction: a) Juridiction professionnelle^ 11° Les dispositions du décret s'appliquent aux établissements représentés par la partie contractante de première part, aux établissements particuliers signataires de la convention, à tous les détaillants en fourrure faisant affaires dans la juridiction territoriale décrite au paragraphe \"b\" du présent article, ainsi qu'à tous les contracteurs et sous-contracteurs exécutant les ordres ou le travail des assujettis ci-haut énumérés, et à tous les salariés ouvriers qualifiés et apprentis, à leur emploi.\" 2° La paragraphe \"a\" de l'article III sera remplacé par le suivant: \"III.Durée du Travail: a) La semaine régulière de travail est de quarante (40) heures distribuées en journées de huit (8) heures, comme suit: Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8.00 a.m.jusqu'à 12.00 p.m.(midi) de 1.00 p.m.jusqu'à 5.00 p.m.ou entre 8.30 a.m.et midi et 1.00 p.m.et 5.30 p.m.pour les ateliers qui auraient la permission du Comité paritaire.Tout travail exécuté en dehors de ces heures est , considéré comme travail supplémentaire et doit être rémunéré à raison de salaire et demi en tout temps de l'année.Toutefois, malgré les dispositions de l'alinéa précédent, un salarié qui se rapporte en retard à son travail par sa faute doit compléter le nombre régulier d'heures de travail pour ce jour avant d'être rémunéré à raison de temps et demi.Exception: Nonobstant les dispositions précédentes, un employeur peut faire faire du travail supplémentaire à ses employés au taux simple pourvu qu'il en ait obtenu l'autorisation écrite du Comité paritaire et qu'il remplisse les conditions ci-après décrites: 1° La limite du travail supplémentaire au taux simple s'étend jusqu'à 9.00 lires p.m.les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi inclusivement, et de 8.00 a.m.à 5.00 hres p.m.le samedi.2° Le travail supplémentaire est prohibé pour la période comprise entre le 1er juin et la fête du Travail.3° Les employés demeurent libres d'accepter ou de refuser de travailler des heures supplémentaires.4° L'employeur doit fournir deux (2) heures de travail l'année suivante pour chaque heure de travail supplémentaire fait à taux simple durant les douze mois de calendrier de l'année précédente; ces heures garanties devront être fournies du 15 janvier au 30 avril par l'employeur qui s'engage à les répartir par semaine de travail de pas moins de trente-deux (32) heures.Exemple: Un employé a fait 200 heures de .travail supplémentaire a taux simple durant 1967.A compter du 15 janvier 1958, l'employeur devra faire travailler «on employé jusqu'à ce que celui-ci ait fait au moins 400 heures d'ouvrage avant le 80 avril 1968, NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio \u2022 Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the fur industry, retail section district of Montreal, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the decree number 643 of May 20th, 1953: 1.Subsection \"a\" of section II will be replaced by the following: \"II.Jurisdiction: a) Professional jurisdiction: 1.The provisions of the decree apply to establishments represented by the contracting party of the first part, to private concerns that signed the agreement and to all retail fur merchants operating within the territorial jurisdiction described in subsection \"b\" of the present section and to all employees, qualified workers and apprentices in their employ.\" 2.Subsection \"a\" of section III will be replaced by the following: \"III.Duration of labour: a) The standard work week shall be of forty (40)hours divided into days of 8 hours each, as follows: On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday: from 8.00 a.m.to 12.00 p.m.(noon); from 1.00 p.m.to 5.00 p.m.or oetween 8.30 a.m.and noon and 1.00 p.m.and 5.30 p.m.for establishments authorized by the Parity Committee.All time worked beyond these hours is considered as overtime and paid for at the rate of time and one half the year round.Notwithstanding the provisions of the foregoing paragraph, an employee late to work by his own fault shall complete the regular number of working hours for that day before being entitled'to the time-and-a-half rate.Exception: Notwithstanding the foregoing provisions, employers may have overtime worked by his employees at straight time providing they obtain a written permission from the Parity Committee to that effect and they comply with the following conditions: .1.Overtime at straight time is permissible until 9.00 p.m.on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday inclusive, and from 8.00 a.m.to 5.00 p.m.on Saturday.2.There shall be no overtime between June 1 and Labour Day.3.Employees are free to accept or refuse to work overtime.4.Employers shall guarantee two (2) hours of work in the following year for every overtime hour worked at straight time in the twelve calendar months of the preceding year; such hours shall be worked from January 15 to April 30 and the employer shall divide them into work weeks of at least thirty-two (32) hours.Exemple: An employee has worked 200 hours of overtime at straight time in 1957.From January 15, 1958, the employer shall give him xvork to the extent of 400 hours, at least, before April 80, 1958, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 2763 5° A tout employé travaillant le soir, l'employeur donnera un ($1.00) dollar pour défrayer le coût de son souper.6° Les employeurs devront s'abstenir en tout temps de faire exécuter du travail de la fourrure à l'extérieur de leur atelier, sauf les cas où les employés-refusent de faire du travail supplémentaire ou ne peuvent, même en faisant tel travail, remplir à temps les commandes de l'employeur.7° Tout employeur qui enfreint ces règlements et congédie ou suspend un ou plusieurs employés, devra obligatoirement rembourser le surtemps qui est dû, dans les délais légaux.8° Un employé qui en aucun temps, quitte volontairement son emploi perd, par le fait même, tout recours contre son employeur quant au recouvrement du surtemps.\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoire ces dispositions avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 3 août 1957.45483-o 5.Employers shall give $1.00 to employee* working in the evening to pay for the evening i meal.6.Employers shall not give fur trade work to be executed outside their establishment except when employees refuse to work overtime or cannot, even when working overtime, do all the work requested by the employers.7.Any employer who does not abide by these provisions and dismisses or suspends one or more employees shall reimburse overtime owed within the legal delays.8.Employees who voluntarily leave their employer shall forfeit their right to claim from their employer any recovery of overtime.The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments can only be rendered obligatory by an Order-in-Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 3, 1957.45483-o Liquidation, avis de: Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des sociétaires du \"Syndicat Coopératif de St-Marc de Figuery\", tenue à Saint-Marc, 1e 4 juin 1957, il a été résolu que les affaires de ladite société soient liquidées volontairement, et que celle-ci soit dissoute, conformément aux dispositions de la Loi des syndicats coopératifs de Québec et de la Loi de la liquidation volontaire des compagnies à fonds social, et que MM.Ena McNeil, Léo Nolet et Clarence Roy ont été nommés liquidateurs.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le dix-neuf juillet 1957.Le Sous-secrétaire de la province, 45490-O JEAN BRUCHÉSI.Winding up Notice: Notice is hereby given that at a general meeting of the members of the Syndicat Coopératif de St-Marc de Figuery, held at Saint-Marc, on June 4, 1957, a resolution was adopted to the effect tbat the affairs of the said association be wound up voluntarily, and that it be dissolved, in accordance with the provisions of the Quebec Cooperative Syndicates' Act, and the Winding-up Act, and for such purposes, that Messrs.Ena McNeil, Léo Nolet, and Clarence Roy have been appointed liquidators.Given at the office of the Provincial Secretary, Julv nineteenth, 1957.JEAN BRUCHÉSI, 45490 Under Secretary of the Province.Ministère des Finances Department of Finance Assurances Insurances Avis d'annulation d'enregistrement Notice of Cancellation of Registration Attendu que \"World Fire and Marine Insu- Whereas \"World Fire and Marine Insurance ranee Company\", dont le siège social est situé à Company\", whose head office is situate in Hart-Hartford, Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, ford, Connecticut, United States of America, has a réassuré toutes ses affaires dans la province de reinsured all his business in the Province of Que-Québec auprès de \"Aetna Insurance Company\", bee with \"Aetna Insurance Company\", whose dont le siège social est situé à Hartford Connec- head office is situate in Hartford, Connecticut, tient, Etats-Unis d'Amérique, en vertu d'un con- United States of America, according to a reinsu-trat de réassurance intervenu entre ces deux com- ranee agreement entered into by these two compagnies le 18 juin 1957, et qui a pris effet le 29 panics on the.l8th of June, 1957, and which has juin 1957; taken effect on the 29th of June, 1957; Attendu que \"World Fire and Marine Insu- Whereas \"World Fire and Marine Insurance ranee Company\" s'est conformée aux dispositions Company\" 1ms complied with the provisions of He l'article 103 de la Loi des assurances; section 103 of the Quebec Insurance Act; En conséquence, avis est par les présentes Consequently, notice is hereby given that the donné que l'enregistrement de \"World Fire and registration of \"World Fire and Marine Insuran- 2764 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 août 1957, Tome 89, N° 31 Marine Insurance Company\" est annulé à comp- ce Company\" is cancelled as from the 1st of ter du 1er juillet 1957.July ,1957.Donné au bureau «lu Service des assurances, Given at the office of the Insurance Brandi, Ministère des finances, le 17 juillet 1957.Department of Finance, on the 17th of July 1957.Pour le Ministre des finances de la province, For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LA FRANCE, GEORGES LAFRANCE, 45459-30-2-o Surintendent.des assurances.45459-30-2-o Superintendent of Insurance.Nominations Appointments Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur, dé l'avis et du consentement du Conseil Exécutif, et par commission, de faire la nomination suivante: Québec, le 12 juin 1957.M.Lionel Fortin, de L'a Tuque, greffier de la Cour de magistrat siégeant à La Tuque, comté de Laviolette, et député-protonotaire de la Cour supérieure pour les district judiciaires de Québec et des Trois-Rivières et siégeant à La Tuque: commissaire \"per dedimus potestatem\" pour recevoir, dans la province, les serments que (les personnes nommés en vertu de la Loi du service civil ou nommées à des emplois publics sont tenues de prêter.45482-0 LISTE DES PRESIDENTS D'ÊLE' His Honor, the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the Executive Council and by Commission, to make the following appointment: Quebec, June 12, 1957.M.Lionel Fortin, of La Tuque, clerk of the Court of Magistrate sitting at La Tuque, county of Laviolette, and Deputy-Prothonotary of the Superior Court for the judicial districts of Quebec and Trois-Rivières and sitting at La Tuque: Commissioner \"per dedimus potestatem\" to receive, in the Province, the oaths that the persons appointed under the Civil Service Act or who are appointed to public office are obliged to swear to, in such functions.45482 \u2022î \u2014 LIST OF RETURNING-OFFICERS District électoral Electoral District\tNoms Names\tProfession ou métier Profession or calling\tAdresse du bureau officiel Address of official office Vaudreuil-Soulangcs.\tLaberge, Joscph-Emilo.\tCommerçant \u2014 Trader .Régistrateur \u2014 Registrar.\tCMteauguay Village.P.Q.10, ruo Garnèau St., East-Angus, P.Q.456, rue Bennett Nord \u2014 (North St.), Thetford-Mines, P.Q.Rue St-François St., Hi-gaud, P.Q.Le present avis est donné conformément à The present notice is given in conformity l'article 20, de la Loi électorale de Québec.with the article 20.of the Quebec Election Act.Québec, le 29 juillet 1957.Quebec, July 29th.1957.Le Président général des élections, FRANÇOIS DROUIN, Q.C., 45493-0 FRANÇOIS DROUIN, C.R.45493-o Chief Returning-Officcr.Office des Marchés Agricoles du Québec AVIS Un projet de plan conjoint présenté par \"l'Association des Jardiniers Maraîchers de la Région de Montréal Inc.\", comprenant les produits agricoles suivants: \"Le Céleri produit en pleine terre, destiné à la consommation à l'état frais seulement, vendu et livré aux grossistes détaillants ou autres acheteurs par les producteurs des comtés de Bagot, Beauharnois, Berthier, Chambly.Châteauguay, Deux-Montagnes, Hochelaga, Iberville.Jacques-Cartier, Joliette, Laprairie, L'Assomption, Laval, Missisquoi, St-Jean, Soulanges, Terrebonne, Vaudreuil et Verchères\" a été reçu et approuvé pour enquête et adjudication finale au mérite.Montréal, 29 juillet 1957.Le Président, (Juge) GEORGES-H.HÉON.Le Secrétaire, 45506-o LÉONARD ROY.Quebec Agricultural Marketing Board NOTICE A petition for a joint marketing plan presented by \"L'Association des Jardiniers Maraîchers de la Région de Montréal Inc.\", for the following agricultural products: \"Field-grown celery, for fresh market only, sold and delivered to wholesalers, retailers or other buyers by the producers of the following counties: Bagot, Beauharnois, Berthier, Chambly, Châteauguay, Deux-Montagnes, Hochelaga.Iberville, Jacques-Cartier, Joliette, Laprairie, L'Assomption, Laval, Missisquoi, St-Jean.Soulanges, Terrebonne, Vaudreuil and Verchères\", has been duly received and approved for investigation and final adjudication on its merits.Montreal, Julv 29th, 1957.(Judge) GEORGES-H.HÉON, Chairman.LÉONARD ROY, 45506-o Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 270.5 AVIS Un projet de plan conjoint présenté par \"l'Association des Jardiniers Maraîchers de la Région de Montréal Inc.,\" comprenant les produits agricoles suivants: \"Les légumes et petits fruits destinés à la consommation à l'état frais seulement, vendus et livrés par les producteurs aux grossistes, détaillants ou autres acheteurs dans les comtés de Magot, Beauharnois, Berthier, Chambly Châ-tcauguay, Deux-Montagnes, Ilochelaga, Iberville, Jacques-Cartier, Joliette, Laprairic, L'Assomption, Laval, Missisquoi, Napierville, Richelieu, Rouville, St-Hyacinthe, St.Jean, Soulanges, Terrebonne, Vaudreuil et Verchères\", a été reçu et approuvé pour enquête et adjudication finale au mérite.Montréal, 29 juillet 1957.Le Président, (Juge) GEORGES-H.HÉON.Le Secrétaire, IÔ506-o LÉONARD ROY.AVIS Un projet de plan conjoint présenté par \"le Syndicat des Producteurs-fournisseurs de lait de la Crémerie Crete Inc., (U.C.C.)\" comprenant les produits agricoles suivants: \"Produits laitiers livrés par les producteurs-fournisseurs du Québec à la Crémerie Crete Inc., de Grand-Mère, comté de Laviolette\", a été reçu et approuvé pour enquête et adjudication finale au mérite.Montréal, ce 29ième jour de juillet 1957.Le Président, (Juge) GEORGES-H.HÉON.Le Secrétaire, 15506-O LÉONARD ROY.Sièges sociaux Avis est, par les présentes donné que la compagnie Chibtown Copper Corporation (Libre de responsabilité personnelle), constituée en corporation par lettres patentes en date du 26ième jour de novembre 1956, et ayant son siège social en la Cité de Montréal, a établi son bureau au N° 266 de la rue St-Jacques, ouest, chambre 414.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 22ième jour de juillet 1957.Chibtown Copper Corporation (LRP).Par le Secrétaire, 45504-o R.BERRY.Marcel Duquette Ltée La compagnie a été incorporée par lettres patentes émises par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, le 15 avril 1957.Sa principale place d'affaires dans la province de Québec est à Brucy, Ile Perrot.Brucy, Ile Perrot, ce 26e jour de juillet 1957.Le Président, .45517-o MARCEL DUQUETTE.NOTICE A petition for a joint marketing plan presenter! by L'Association des Jardiniers Maraîchers de la Région de Montréal Inc.\" for the following agricultural products: \"Vegetables and small fruits for fresh market only, sold and delivered to wholesalers, retailers or other buyers by the producers of the following counties: Bagot, Beauharnois, Berthier, Chambly, Chfiteauguay, Deux-Montagnes, Hochclaga, Iberville, Jacques-Cartier, Joliette, Laprairie, L'Assomption, Laval, Missisquoi, Napierville, Richelieu, Rouville, St-Hyacinthe, St.Jean, Soulanges, Terrebonne, Vaudreuil et Verchères\", has been duly received and approved for investigation and final adjudication on its merits.Montreal, Julv 29th, 1957.(Judge) GEORGES-H.HÉON, Chairman.LÉONARD ROY, 45506-O Secretary.NOTICE A petition for a joint marketing plan presented by \"Le Syndicat des producteurs-fournisseurs de lait à la Crémerie Crete Inc., (U.C.C.)\" for the following agricultural products: \"Dairy products delivered by the producers-suppliers in the Province of Quebec to the plant Crémerie Crete Inc., Grand-Mère, county of Laviolette, P.Q.\", has been duly received and approved for investigation and final adjudication on its merits.Montreal, Julv 29th, 1957.(Judge) GEORGES-H.HÉON, Chairman.LÉONARD ROY.45506-o Secretary.Head Offices Notice is hereby given that the Ch ibtown Copper Corporation (No Personal Liability) company incorporated by letters pate'nt, on the 26th day of November 1956, and having its head office in the city and district of Montreal, has established its office at 266 St.James St.West, room 414.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being Jthe Head Office of the company.Dated at Montreal, this 22nd dav of July, 1957.Chibtown Copper Corporation (NPL).R.BERRY, 45504-O per: Secretary.Marcel Duquette Ltke The company has been incorporated by letters patent issued by the Lieutenant-Governor of the Province on April 15.1957.Its head office in the Province of Quebec, is at Brucy, He Perrot.Brucv, He Perrot, July 26, 1957.MARCEL DUQUETTE, 45517 President. 2766 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 août 1957, Tome 89, N* 31 Avis est, par les présentes, donné que la compagnie Bowes Construction Co.Limited, constituée en corporation par lettres patentes en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, le 13e jour de février 1957, et ayant son siège social en la cité de Montréal, province de Québec, a établi son bureau à 6902 Côte-des-Nciges, Montréal, P.Q.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, P.Q., ce 29e jour de juillet 1957.Le Président, 45515 ' ROY C.BOWES.(P.G.10051-57) Esker Quebec Mines Limited (No Personal Liability) Règlement Numéro six Un règlement qui change la situation du siège social de la compagnie.i \"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de Esker Quebec Mines Limited (No Personal Liability) que la situation du siège social de la compagnie soit et elle est, par les présentes, changée de la cité de Québec à la cité de Montréal, province de Québec.\" Je certifie, par les présentes, que le précédent est une vraie et authentique copie du règlement numéro six de Esker Quebec Mines Limited (No Personal Liability) passé par les directeurs le 26e jour de juin 1957, et confirmé par les actionnaires de la compagnie le 26 juin 1957, par un vote unanime de tous les actionnaires présents.Témoins: Le Sceau corporatif de la compagnie et ma signature comme son secrétaire, ce 3c jour de juillet 1957.(Sceau) Le Secrétaire, 45516 JACQUES DE BILLY.W.A.Beattie Sales Ltd.La compagnie a été constituée en corporation par lettres patentes accordées par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec en date du 18 mai 1957.Son siège social dans la province de Québec est à St-Jovitc.Signé à St-Jovite, ce 30e jour de juillet 1957.Le Président, 45518 W.H.BEATTIE.(P.G.11101-57) Volkswagen Sales & Service Ltd.Règlement spécial \"D\" Le siège social de la compagnie autrefois situé à 1922 rue Ste.-Catherine ouest, Montréal, Que., sera à compter de ce jour situé à 5465 avenue Royal Mount, Ville Mont-Royal, Province de Québec.Je certifie par les présentes que le règlement précité a été édicté par les administrateurs de Volkswagen Sales & Service Ltd., à une séance tenue le 22 juin 1957, et a été sanctionné à une assemblée spéciale générale des actionnaires à laquelle tous les actionnaires étaient présents, tenue le même jour.Montréal, Que.4 juillet 1957.Le Secrétaire, 45505-o MARCEL PICHÉ.Notice is hereby given that Bowes Construction Co.Limited, incorporated by letters patent under Part I of the Quebec Companies' Act, on the 13th day of February, 1957, and having its Head Office in the city of Montreal, Province of Quebec, has established its office at 6902 Côte-des-Neiges, Montreal, P.Q.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the Head Office of the company.Dated at Montreal, P.Q., this 29th dav of Julv.1957.ROY C.BOWES, 45515-0 President.(A.G.10051-57) Esker Quebec Mines Limited (No Personal Liability) By-law number six A by-law changing the location of the Head Office of the company.\"Be it enacte and it is hereby enacted as a by-law of Esker Quebec Mines Limited (No Personal Liability) that the location of the Hea'd Office of the company be and the same is hereby changed from the city of Quebec to the city of Montreal in the Province of Quebec.\" I hereby certify that the foregoing is a true copy of By-law number six of Esker Quel.ee Mines Limited (No Personal Liability) pas.-ed by the Directors on June 26th, 1957, and confirmed by the shareholders of the company on June 26th, 1957, by the unanimous vote of all shareholders present.Witness the Corporate Seal of the company and my hand as Secretary thereof this 3rd dav of July, 1957.(Seal) JACQUES DE BILLY, 45516-o Secretary.W.A.Beattie Sales Ltd.The company was incorporated by letters patent granted by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec on May the 18th, 1957.Its principal place of business in the Province of Quebec is at St-Jovite.Signed at St-Jovite, this 30th day of July, 1957.W.H.BEATTIE.45518-0 President.(A.G.11101-57) Volkswagen Sales\" & Service Ltd.Special By-law \"D\" The Head Office of the company formerly located at 1922 St.Catherine St.West, Montreal, Que., shall as of to-day, be located at 5405 Royal Mount Avenue, Town of Mount Royal, Province of Quebec.I hereby certify that the above by-law was enacted by the directors of Volkswagen Sales & Service Ltd., at a meeting held on June 22nd.1957, and was ratified at a special general meeting of the shareholders, at which all tlie shareholders were present, held the same day.Montreal, Que July 4th 1957.MARCEL PICHÉ.45505-o \u2022 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.81 2767 ' Soumissions Province de Québec Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Notre-Dame-du-Lac (Comté de Témiscouata) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Charles-E, Cliche, Notaire, secrétaire-trésorier, Notre-Dame-du-Lac, comté de Témiscouata, jusqu'à 7.30 hrs.p.m.lundi, le 19 août 1957, pour l'achat de §166,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de \\'otre-Dame-du-Lac, comté de Témiscouata, datées du 1er septembre 1957 et remboursables, par séries du 1er septembre 1958 au 1er septembre 1977 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 43^% ni supérieur à 5^% par année, payable semi-annuellcmeut les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'cnnprunt en date du 6 juin 1957 \u2014 construction d'une école pour les garçons, et dépenses incidentes.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er septembre 1957.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $166,000.00 \u2014 20 ans Année Capital \t.x 829,500\t00 ' 1er septembre 1959.\tx 31,000\t00 1er septembre 1960.\tx 33,000\t00 1er septembre 1961\t2,500\t00 1er septembre 1962.\t3,000\t00 1er septembre 1963.\t3,000\t00 1er septembre 1964.\t3,000\t00 1er septembre 1965.\t3,500\t00 1er septembre 1966.\t3,500\t00 1er septembre 1967.\t3,500\t00 1er septembre 1968.\t4,000\t00 1er septembre 1969.\t4,000\t00 1er septembre 1970.\t4,500\t00 1er septembre 1971, , .\t4,500\t00 1er septembre 1972.\t5,000\t00 1er septembre-1973.\t5,000\t00 1er septembre 1974.\t5,500\t00 1er septembre 1975.\t5,500\t00 1er septembre 1976.\t6,000\t00 1er septembre 1977.\t6,500\t00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $95,850.00 accordé par le Secrétaire de la province et payable en trois versements de $31,950.00 chacun, de 1958 à 1960 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.De plus, des soumissions pourront être envoyées et seront considérées pour des obligations à courte échéance dix ans et à courte échéance quinze ans.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engagea payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Cabano, comté de Témiscouata.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er septembre 1964 Tenders Province of Quebec The School Commissioners for the Municipality of Notre-Dame du-Lac (County of Témiscouata) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Charles-E.Cliche, notary, Secretary-Treasurer, Notre-Dame-du-Lac, county of Témiscouata, until 7.30 o'clock p.m., Monday, August 19, 1957, for the purchase Of an issue of $166,000.00 of bonds of the School Commissioners for the municipality of Notre-Dame-du-Lac, county of Témiscouata, dated September 1st, 1957 and redeemable serially from September 1st, 1958 to September 1st, 1977 inclusively, with interest at a rate not less than tyfflo nor more than 5}4% per annum, payable semi-annually on March jst and Spetember 1st, of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated June 6, 1957 \u2014 construction a school for boys and incidental expenses.For adjudication purposes only, interest shall be computed as from September 1st, 1957.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $166,000.00 \u2014 20 years Year Capital September 1st, 1958.x $29,500.00 September 1st, 1959.x 31,000.00 September 1st, 1960.x 33,000.00 September 1 st, 1961.2,500.00 September 1st, 1962.3,000.00 September 1st, 1963.3,000.00 September 1st, 1964.3,000.00 September 1st, 1965.3,500.00 September 1 st, 1966.3,500.00 September 1st, 1967 .3,500.00 September 1st, 1968.4,000.00 September 1st, 1969.' 4,000.00 September 1st, 1970.4,500.00 September 1st, 1971.4,500.00 September 1 st, 1972.5,000.00 September 1st, 1973 .5,000.00 September 1st, 1974.5,500.00 September 1st, 1975.5.50Q.00 September 1st, 1976.6,000.00 September 1st, 1977.6,500.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $95,850.00 granted by the Provincial Secretary and payable in three instalments of $31,950.00 each, from 1958 to 1960 inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan.Moreover tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and acrrued interest if any, by certified cheque payable at par at Cabano, county of Témiscouata.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemable by anticipation prior to September 1st, 1964 inclu- inclusivement si elles sont émises à courte échéance 10 ans, avant le 1er septembre 1965 inclusivement si elles sont émises à courte échéance 15 ans, et avant le 1er septembre 1967 inclusivement si elles sont émises pour le terme de vingt ans; après ces dates, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il* affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 19 août 1957.à 7.30 heures p.m., en la.salle de l'école du village, Notrc-Dame-du-Lnc, comté de Témiscouata.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Notre-Dame-du-Lac, (Comté de Témiscouata), ce 30 juillet 1957.Le Secrétaire-trésorier, CHARLES-E.CLICHE, Notaire.Notre-Dame-du-Lac, (Comté de Témiscouata), P.Q.45507-O Province de Québec sive if issued as ten-year short-term bonds, prior to September 1st, 1965 inclusive if issued as fifteen -year short-term bonds, and prior to September 1st, 1967 inclusive if issued for a\" twenty-year term; after which dates, the said bonds are, under the authority of Chpater 212, Revised' Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Monday, August 19, 1957 at 7.30 o'clock p.m., at the School Hall of the Village, Notre-Dame-du-Lac, county of Témiscouata.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Notre-Dame-du-Lac, (County of Témiscouata), July 30, 1957.CHARLES-E.CLICHE, Notary, Secretary-Treasurer.Notre-Dame-du-Lac, (County of Témiscouata), P.Q.45507 Province of Quebec JjBs commissaires d'écoles pour la munici- The School Commissioners for the municipalité de St-Georges-de-Windsor pality of St-Georges-de-Windsor (Comté de Richmond) (County of Richmond) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Jean-V.Lépinè; secrétaire-trésorier, St-Georges-de-Windsor, comté de Richmond, jusqu'à 8.00 hrs.p.m., mardi, le 20 août 1957, pour l'achat de SI 10,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de St-Georges-de-Windsor, comté de Richmond, datées du 1er août 1957 et remboursables par séries du 1er août 1958 au 1er août 1967 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4J^% ni supérieur à Par année, payable semi-annuellement les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 24 juin 1957 \u2014 construction d'un couvent et dépenses incidentes.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er septembre 1957.Le tableau d'amortissement est le suivant Tableau d'amortissement \u2014 $110,000.00 \u2014 10 ans Année Capital 1er août 1958.x $24,000.00 1er août 1959.x 25,500.00 1er août 1960.x 27,000.00 1er août 1961.4,000.00 1er août 1962.4,500.00 1er août 1963.4,500.00 1er août 1964.4,500.00 1er août 1965.5,000.00 1er août 1966.5,500.00 1er août 1967 .5,500.00 Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Jean-B.Lépine, secretary-treasurer, St-Georges-de-Windsor, county of Richmond, until 8.00 o'clock p.m., Tuesday, August 20, 1957, for the purchase of an issue of $110,000.00 of bonds of the School Commissioners for the municipality of St-Georges-de-Windsor, county of Richmond, dated August 1st, 1957 and redeemable serially from August 1st, 1958 to August 1st, 1967 inclusively, with interest at a rate not less than 4j^% nor more than 5l/>% per annum, payable semi-annually on February 1st and August 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated June 24, 1957 \u2014 construction of a convent and incidental expenses.For purposes of adjudication only, interest shall be computed as from September 1st, 1957.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $110,000.00 \u2014 là years Year Capital August 1st, 1958.x $24,000.00 August 1st, 1959.x 25,500.00 August 1st, 1960.x 27,000.00 August 1st, 1961.4,000.00 August 1st, 1962.4,500.00 August 1st, 1963.4,500.00 August 1st, 1964.4,500.00 August 1st, 1965.5,000.00 August 1st, 1966.5,500.00 August 1st, 1967.5,500.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles The letters \"x\" indicate the years during which les versements annuels d'un octroi total de annual payments of a total amount of $72,750, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1957, Vol.89, No.31 2769 $72,750, accordé par le Secrétaire de la province et payable en trois versements de $24,250 chacun, de 1958 à 1960 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Asbestos, comté de Richmond.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont Icjiom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesditcs obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er août 1964 inclusivement; après cette date, lesditcs obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% «lu montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend, ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 20 août 1957, à 8.00 heures p.m., au lieu ordinaire des séances, à St-Georges-de-Windsor, comté de Richmond.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Georges-de-Windsor, (Comté de Richmond), ce 30 juillet 1957.Le Secrétaire-trésorier, JEAN-B.LÉPINE.St-Georges-de-Windsor, (Comté de Richmond), P.Q.45508-o granted by the Provincial Secretary and payable in three instalments of 824,250 each, from 1958 to 1960 inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Asbestos, county of Richmond.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemable by anticipation before August 1st, 1964 inclusively, after this date, the said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Tuesday, August 20, 1957, at 8.00 o'clock p.m., at the ordinary meeting place, at St-Gcorges-de-Windsor, county of Richmond.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.St-Georges-de-Windsor, (County of Richmond), July 30, 1957.JEAN-B.LÉPINE, Secretary-Treasurer.St-Georges-de-Windsor, (County of Richmond), P.Q.45508 Ventes \u2014 Loi de faillites Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure N° 247 (1949).\"En faillite\".Dans l'affaire de la faillite de Paul J.Garnier, iMascouche, district de Joliette, P.Q., cédant autorisé, et Claude Perras, Syndic.AVIS DE VENTE Avis public est par les présentes donné que l'immeuble suivant, savoir: Description: 1° \"Un lot de terre situé dans la paroisse de St-Henri de Mascouche, à Terrebonne Heights, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de ladite paroisse de St-Henri de Mascouche comme étant le lot soixante-onze de la subdivision officielle du lot sept cent quatre-vingt-un E (781-E-71), contenant cinquante pieds de largeur par cent quatre-vingt-douze pieds de longueur, plus ou moins, mesure anglaise, ayant front sur le chemin de la Station, en arrière par le lot 781-89, d'un côté par 781-E-70 et de l'autre «'lté par le lot 781-E-72, sans bâtisse.\" 2° \"Un emplacement situé à Terrebonne Heights; en la paroisse de St-Henri dd Mascouche, connu et désigné sous le numéro soixante-dix, de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept cent quatre-vingt-un E (N° 781-E-70) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Henri de Mascouche, contenant cinquante pieds en front par cent quatre-vingt-douze pieds en profondeur, et borné en front par le chemin de Sales \u2014 Bankrupcy Act Province of Quebec, district of Montreal, No.247 (1959), Superior Court, \"in bankruptcy\".In the affair of the bankruptcy of: Paul J.Garnier, Mascouche, District of Joliette, P.Q., authorized assignor, and Claude Perras, trustee.NOTICE OF SALE Public notice is given, by these presents that the following immoveable, to wit: Designation: 1.\"A lot of land situated in the parish of St-Henri de Mascouche, at Terrebonne Heights, known and designated on the official plan and book of reference for the said parish of St-Henri de Mascouche, as lot seventy-one of the official subdivision of lot seven hundred and eighty-one E (781-E-71), containing fifty feet in width by one hundred and ninety-two feet in length, more or less, English measure, fronting on Station Rd., on rear by lot 781-89, on one side by 781-E-70 and the other side by lot 781-E-72, without building.\" 2.\"An emplacement situated at Terrebonne Heights, in the parish of St.Henri de Mascouche, known and designated under number seventy, of the official subdivision of the original lot number seven hundred and eighty-one-E (No.781-E-70) on the'official plan and book of reference of the parish of St.Henri de Mascouche, containing fifty feet in front by one hundred and ninety-two feet in depth, and bounded in front by the la station, en arrière par Mr.Pyke, d'un côté par le lot N° 781-E-71 et de l'autre côté par Betrix Wood; avec toutes bâtisses y érigées; le tout mesure anglaise et plus ou moins.\"' Seront vendus comme une seule et môme exploitation à la porte de l'église paroissiale de Mascouche, comté de l'Assomption, à ONZE heures de l'avant-midi, VENDRDI, le TRENTE AOÛT 1957.Cette vente est faite en vertu d'un jugement rendu par la Cour Supérieure à Montréal, Je 5 juillet 1957, et suivant les dispositions des articles 55 et suivants de la Loi de 1949 sur la faillite, afin de donner à cette vente l'effet du décret aux termes du Code de procédure civile.Condition: Comptant.En plus du prix d'acquisition, l'acquéreur devra payer les droits du Gouvernement 2%% conformément à la Loi.Pour autres renseignements et cahier des charges d'adresser au soussigné.Daté à Montréal, ce 12 juillet 1957^ Le Syndic, CLAUDE PERRAS.Bureau de Perras & Perras, Syndics, 4 est rue Notre-Dame, Montréal, P.Q.45460-30-2 station road, in rear by Mr.Pyke, on one side by lot No.781-E-71 and on the other side by Betrix Wood; with all building thereon erected; the whole English measure, and more or less.\" Shall be sold as a one and only concern at thç parish church of Mascouche, county of jl'Assomption, at ELEVEN o'clock in the forenoon FRIDAY, the THIRTIETH day of AUGUST, 1957.This sale is made under a judgment rendered by the Superior Court at Montreal, on July 5, 1957, and according to the provisions of section 55 and following of the Act 1949 on bankruptcy, so as to give to this sale the effect of a sale by Sheriff in accordance with the Code of Civil Procedure.Conditions: cash.Over and above the purchasing price, the purchaser shall pay the Government tax or 2/^% according to the law.For further information and list of charges, apply to the undersigned.Dated at Montreal, July 12, 1957.CLAUDE PERRAS, Trustee.Office of Perras & Perras, trustees, 4 Notre-Dame Street, East, Montreal, P.Q.45460-30-2 Canada, Province de Québec, District de Que- Canada, Province of Quebec, district of Quebec, N° 5722-F.Dans la Cour Supérieure (En beç, No.5722-F.In the Superior Court (In Matière de Faillite).Dans l'affaire de: Antonio Bankruptcy).In the matter of : Antonio Picard, Picard, chauffeur de camion, 372, Avenue San- truck driver, 372, Santerre Avenue, Quebec terre, Québec ouest, P.Q.Ouest, P.Q.VENTE A L'ENCAN.Avis est par les présentes donné que MARDI, le DIX SEPTEMBRE, 1957, à ONZE bourse a.m., sera vendu par encan public, à mon bureau, 71, rue St-Pierre, Chambre 411, Québec, P.Q., l'immeuble ci-après décrit, savoir: \"Un immeuble connu et désigné comme étant les subdivisions 91 et 92 du lot originaire 2428 du cadastre officiel pour la paroisse de St-Sauveur de Québec, avec la maison dessus construite, circonstances et dépendances.\" Cet immeuble sera vendu au plus haut et dernier enchérisseur.Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressant aux bureaux du syndic sous-signé.Cette vente sera faite conformément aux articles 716, 717 et 719 A du Code de procédure civile et aussi à l'article 55 de la loi de faillite.Cette vente équivaut à la vente faite par le Shérif.Conditions de paiement: Argent comptant.Québec, ce 30 juillet, 1957.J.P.BÉDARD, Syndic.Bureaux: 71, rue St-Pierre, ' Chambre 411, Québec.45519-31-2-0 AUCTION SALE Notice is hercbv given that on TUESDAY, SEPTEMBER TENTH, 1957, at ELEVEN o'clock a.m., will be sold by public auction at my office, 71, St-Peter St., Room 411, Quebec, P.Q., the immovable property as follows: \"An immovable property known as being subdivisions number 91 and 92 of original lot number 2428 of the official cadastre for theparish of St-Sauveur of Quebec, with building hereon constructed, circumstances and dépendances.\" This immovable property shall be sold to the highest and last bidder.Titles and certificates may be examined at any time by applying to the office of the undersigned trustee.This sale shall be made in accordance with articles 716, 717 and 719 A of the code of civil procedure and also to article 55 of the Bankruptcy Act.This sale is the equivalent of a Sheriff Sale.Conditions of pavment: Cash.Quebec, July 30th, 1957.J.P.BÉDARD, Trustee.Offices: 71 St-Pcter, St., Room 411, Quebec.45519-31-2-0 Vente par licitation Canada, province de Québec, district de Trois-Rivières, Cour Supérieure N° 14334.Dame Dora Bourassa, ménagère, épouse séparée de biens de Clovis Jean, surveillant, avec lequel elle demeure et ledit Clovis Jean pour autoriser et assister sadite épouse aux fins des présentes tous deux domiciliés à Shawinigan Sud, demandeurs vs Bourbeau Bourassa, épicier, Sale by Licitation Canada, Province of Quebec, District of Trois-Rivières, Superior Court, No.14334.Dame Dora Bourassa, housewife, wife separate as to property of Clovis Jean, supervisor, with whom she has lived and the said Clovis Jean, to authorize and assist his said wife for these present purposes, both domiciled at Shawinigan-South, plaintiffs, vs Bourbeau Bourassa, grocer, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 3rd, 1967, Vol.89, No.81 2771 Isidore Bourassa, huissier, Albert Bourassa, rentier, tous trois domiciliés à Shawinigan Falls, Lucien Bourrassa, journalier, Jacques Bourassa, journalier, Alfred Bourassa, concierge, tous trois domiciliés à Montréal et Roch Bourassa, sans emploi, domicilié à Ottawa, Ontario, défendeurs.Avis de licitation selon C.P.1047 Avis est, par la présente, donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour supérieure siégeant aux Trois-Rivières, dans le district de Trois-Rivières, le 18 mars 1957, dans cette cause dans laquelle dame Dora Bourassa Jean, ménagère, épouse séparée de biens de Clovis Jean, surveillant, avec lequel elle demeure et ledit Clovis Jean pour autoriser et assister sadite épouse aux fins des présentes tous deux domiciliés à Shawinigan Sud sont demandeurs, ordonnant la licitation de certains immeubles désignés comme suit, savoir: \"Un emplacement situé à Shawinigan Falls, connu et désigné comme étant le lot numéro 53 de la subdivision du lot numéro six cent vingt-huit (628-53) aux plan et livre de renvoi officiel pour la paroisse de Ste-Flore, mesurant 50' de largeur par 92' de profondeur, mesure anglaise plus ou moins, borné en front par la 3e rue, en arrière par la ruelle, du côté est par le lot 628-52 et du côté ouest par le lot numéro 628-54 des plan et livre de renvoi officiel avec ensemble la maison et autres bâtisses y érigées\", L'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur le VINGT-QUATRIÈME jour de SEPTEMBRE 1957, Cour tenante, dans la salle d'audience du Palais de Justice de Trois-Rivières, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposées au greffe du Protonotaire de ladite Cour; Et que toute opposition afin d'annuler, afin de charge ou afin de distraire à ladite licitation, devra être déposé au greffe du Protonotaire de ladite Cour au moins 12 jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication et que toute opposition afin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication; Et à défaut par les parties de déposer lesdites oppositions dans le délai prescrit par la présente, elles seront forcloses du droit de le faire; Trois-Rivières, le 22 juillet 1957.Vraie copie L'Avocat des demandeurs, 45497-31-2-0 (Signé) ALEX BASTJEN.VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.CHICOUTIMI Fieri Fadas de Terris District de Chicoutimi Cour Supérieure, / t 'OFFICE DU CRÉDIT N° 22,777.I ¦L' AGRICOLE DU QUÉ-v BEC, corps politique et incorporé, ayant son siège social à Québec, requérant, vs JEAN BAPTISTE BOUDREAULT, rang I, Falardeau, comté de Chicoutimi, intimé.Isidore Bourassa, bailiff, Albert Bourassa, annuitant, all three domiciled at Shawinigan Falls, Lucien Bourassa, laborer, Jacques Bourassa, laborer, Alfred Bourassa, janitor, all three domiciled at Montreal, and Roch Bourassa, without employement, domiciled at Ottawa, Ontario, defendants.Notice of Licitation according to C.P.1047 Notice is, by these presents, given that under judgment of the Superior Court sitting at Trois-Rivières, in the district of Trois-Rivières, on March 18, 1957, in this case in which dame Dora Bourassa Jean, housewife, wife separate as to property of Clovis Jean, supervisor, with whom she resides and the said Clovis Jean to authorize and assist his said wife for these present purposes, both domiciled at Shawinigan South, are plaintiffs, ordering the licitation of certain immoveables designated as follows, to wit: \"An emplacement situated at Shawinigan Falls, known and designated as being lot number 53 of the subdivision of lot number six hundred and twenty-eight (628-53) on the official plan and in the book of reference for the parish of Ste-Flore, measuring 50' in width by 92 in depth, English measure, more or less, bounded in front by 3rd street, in rear by the lane, on the east side by lot 628-52 and on the west side by lot number 628-54 on the official plan and in the book of reference together with the house and other buildings thereon erected\", The immoveable above designated shall be sold by auction and adjudged to the highest and last bjdder on the TWENTY-FOURTH day of SEPTEMBER, 1957, in open Court, in the Conference Hall of the City Hall of Trois-Rivières, subject to the charges, clauses and conditions indicated in the list of charges filed in the office of tiie Prothonotary of the said Court; And that any oppositions for cancellation, for purposes of charges or for purposes of withdrawal from the said licitation, shall be filed with the clerk of the Prothonotary of the said Court at least 12 days before the day fixed, as aforesaid, for the said sale, and adjudication, and any opposition for payment must be filed within six days after the adjudication; And in default of the parties to file the said oppositions within the delay prescribed by these presents, they shall be forclosed from the right of doing so; Trois-Rivières, July 22, 1957.True copy (Signed) ALEX.BASTIEN, 45497-31-2 Advocate of the Plaintiffs.SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.CHICOUTIMI Fieri Facias de Terris District of Chicoutimi Superior Court, ( /QUEBEC FARM CRE-No.22,777.{ VÇ DIT BUREAU, a body I politic and incorporate, having its head office at Quebec, petitioner, vs JEAN BAPTISTE BOUDREAULT, Range I, Falardeau, county of Chicoutimi, respondent: 2772 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S août 1967, Tome 89, N° SI kljContre.l'Intimé: Les lots numéros quarantc-et-un-A et qua-rante-deux-A (41-A et 42-A), rang un Est, cadastre officiel du canton Falardeau, avec bâtisses et toutes dépendances.Pour être vendus \"en bloc\" à la porte de l'église paroissiale de St-David de Falardeau, JEUDI, le CLNQULÈME jour du mois de SEPTEMBRE 1957, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, RENÉ DELISLE.Chicoutimi, le 23 juillet 1957.45498-31-2-o JOLIETTE Canada \u2014 Province de Québec District de Joliette Cour Supérieure, / \"D ERTHIERVLLLE AUTO- N° 12,981.< -° MOBILE LTÉE, corps (.politique dûment incorporé, ayant sa principale place d'affaires à Bertnier-ville, district de Joliette, demandeurs et JEAN PAUL BRISSETTE, camionneur, demeurant à l'Ile St-Ignace de Loyola, district de Joliette, défendeur.Comme appartenant au défendeur: \"Une portion de terrain en forme triangulaire, connu et désigné aux plan et livre de renvoi-officiels de la paroisse de l'Ile du Pads, comme faisant partie du numéro cinquante-trois (p53) ayant environ cent pieds de longueur sur une largeur maximum de quarante pieds et allant en diminuant pour se terminer en pointe, le tout tel que clôturé et renfermé dans les bornes suivantes, savoir: d'un côté à la route Berthierville \u2014 St-Ignace de Loyola, d'un autre coté au terrain restant la propriété du vendeur et à la profondeur du terrain de Pierre St-Martin.\" Pour être vendue à la porte de l'église de la paroisse de St-Ignace de Loyola, le MERCREDI, QUATRLEME jour du mois de SEPTEMBRE 1957, à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif de Joliette, ROLAND PERREAULT.Bureau du Shérif, Joliette, ce 29 juillet 1957.45499-31-2-0 KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Kamouraska Cour de Magistrat, t TL/fe NCESLASMI-N° 1070.< VV CHAUD, voyageur (.de Saint-Germain, demandeur, vs EUGÈNE TURCOTTE, de Esprit-Saint, défendeur.\"Le lot numéro trente-neuf (39) du rang trois (3) canton Laroche, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.\" Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de Esprit-Saint, comté de Rimouski, MERCREDI, le QUATORZIÈME jour d'AOÛT, 1957, à DEUX heures de l'après-midi, heure avancée.Le Shérif, Bureau du Shérif, P.E.MARTIN.Rivière-du-Loup, ce 3 juillet 1957.45370-28-2-O [Première insertion samedi, le 13 juillet 1957] Fieri Fadas de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Québec tT L.THÊRIAULT & FILS J- LIMITÉE, corps social et politique légalement cons- Against respondent: Lots numbers forty-one-AJJand forty-tow-A (41-A and 42-A), range one East, official ca-daster of the township of Falardeau, with build, ing and all dependencies.To be sold \"in block\" at the parochial church door of St.David de Falardeau, THURSDAY the FIETH day of the month of SEPTEMBER, at THREE o'clock in the afternoon.RENE DELISLE, Sheriff's Office, Sheriff.Chicoutimi, July 23, 1957.45498-31-2 JOLIETTE Canada \u2014 Province of Quebec District of Joliette Superior Court, / T5ERTHLERVILLE AUTO-No.12,981.< L> MOBILE LTÉE., a bo.\\ dy politic duly incorporated, having its head office at Berthierville, district of Joliette, plaintiff and JEAN PAUL BRISSETTE, trucker, residing at He St-Ignace, of Loyola, district of Joliette, defendant.As belonging to the defendant : \"A portion of land of triangular form known and designated on the official plan and in the book of reference of the parish of He du Pads, as forming part of number fifty-three (Pt.53) having about one hundred feet in length by a maximum width of forty feet and becoming smaller to end in a point, the whole as fenced-in and enclosed within the following boundaries, to wit: on one side by the Berthierville route \u2014 St-Ignace de Loyola, on one side by the land remaining the property of the vendor and on the depth, by the land of Pierre St-Martin.\" To be sold at the church door of the parish of StHgnace of Loyola, on WEDNESDAY, the FOURTH day of the month of SEPTEMBER, 1957, at ELEVEN o'clock in the forenoon.ROLAND PERREAULT, Sheriff of Joliette.Sheriff's Office, Joliette, July 29, 1957.45499-31-2 KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Kamouraska Magistrate's Court, /\\\\/ENCESLAS MI-No.1070.< VV CHAUD, traveller vof Saint Germain, plaintiff vs EUGÈNE TURCOTTE, of Esprit-Saint, defendant.\"Lot number thirty-nine (39) Range three (3) Township Laroche, with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.\" To be sold at the door of the church of the parish of Esprit-Saint, county of Rimouski, WEDNESDAY the FOURTEENTH day of AUGUST 1957, at TWO o'clock in the afternoon, Daylight Saving Time.P.E.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Rivière-du-Loup, this July 3,1957.45370-28-2 [First insertion Saturday, July 13, 1957] Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Quebec \u2022 i t L.THÊRIAULT & FILS No.81,430.) L'emplacement de la maison d'école dudit rang sept.\" Pour être vendu à la porte de l'église de St-Jean de la Lande, comté de Témiscouata, MERCREDI, le QUATRIÈME jour de SEPTEMBRE, 1957, à DIX heures de l'avant-midi, heure avancée.Le Shérif, Bureau du Shérif, P.-E.MARTIN.Rivière-du-Loup, ce 17 juillet 1957.45501-31-2-o [Première insertion: samedi, le 3 août 1957.] MONTMAGNY Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Montmagny Cour Supérieure, ( t A.CLERMONT PEL-N° 7554.< j \u2022 CHAT, négociant, St-v Nazaire, Dorchester, P.Q., rated, with head office at 710 First Avenue, Quebec, plaintiff, vs GEORGES CHOUINARD, Les Étroits, county of Témiscouata, defendant.\"Lot number thirty-seven, range, two (37-2) township Packington, county of Témiscouata, the whole with buildings thereon erected circumstances and dependencies.\" To be sold at the church door of Les Étroits, county of Témiscouata, WEDNESDAY, on the FOURTH day of SEPTEMBER, 1957, at TWO o'clock in the afternoon, Daylight Saving Time.P.-E.MARTIN, Sheriff's Office, - Sheriff.Rivière-du-Loup, July 19, 1957.45500-31-2 [First insertion: Saturday, August 3, 1957.] Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Kamouraska Magistrate's Court, ( \"F\\AME CLAUDIA MO-No.12,767.< *J RIN, widow of Mr.V Napoléon Fradette, of the place called \"Les Étroits\", in the county of Témiscouata, plaintiff, vs IGNACE BÉLANGER, of St-Jean de la Lande (Lake Thibeault), defendant.\"A lot of land, together with the buildings thereon erected, situated in the parish of St-Jean de la Lande, county of Témiscouata, known and designated on the official cadaster of the township of Robinson, under number thirty of range seven (lot No.30/range VII, Robinson,) measuring according to the primitive survey thirteen chains, fourteen links in width by a medium depth of seventy-eight chains, sixty links, containing an area according to the said survey one hundred and two and nine tenths acres, but containing in area, following contentes given by letters patent hereinafter mentioned, ninety-five acres, bounded on the northwest partly by lot number twenty-nine on the same range and partly by the emplacement of Mr.Ronaldo Nadeau, on the northeast by the line between ranges seven and eight, on the southeast, by lot number thirty-one of the same range, and on the southwest, partly by the above said emplacement and partly by the line between ranges 6 and 7.To withdraw from its primitive survey: a) An emplacement in the form of a square, situated at the angle northwest of the said lot, measuring more or less 360 English feet on the side, containing three acres in area, transferred by the borrower to Mr.Ronaldo Nadeau following deed of transfer dated October 12, 1938.b) The emplacement of the school house of the said range seven.\" To be sold at the church door of St.Jean de la Lande, county of Témiscouata, WEDNESDAY, the FOURTH day of SEPTEMBER, 1957, at TEN o'clock in the forenoon, Daylight Saving Time.P.-E.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Rivière-du-Loup, July 17, 1957.45501-31-2 [First insertion: Saturday, August 3, 1957.] MONTMAGNY Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Montmagny Superior Court, (J A.CLERMONT PEL-No.7554.< j \u2022 CHAT, dealer, St.Nazai-l re, Dorchester, P.Q., plain- 2774 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S août 1957, Tome 89, N° SI demandeur vs ROBERT BLAIS, St-Paul du Buton, comté de Montmagny, défendeur.Une ferme située en la municipalité de St-Pliilémon, comte de Bellccliasse, désignée sous le numéro trentc-neuf-B (39-B) du quatrième rang (IV) du canton Mailloux, avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances; tel que le tout se trouve actuellement avec les servitudes actives et passives.Pour être vendu à la porte de l'église de St-Pbilémon, comté de Bellecbasse, JEUDI le CINQUIEME jour de SEPTEMBRE 1957, à DEUX heures et DEMIE de l'après midi (2]/2 heures P.M.) Le SI i S rif Bureau du Shérif, CHS.OMER BERNLER.Montmagny, le 29 juillet 1957.45502-31-2-o tiff, vs ROBERT BLAIS, St.Paul de Buton, county of Montmagny, defendant.A farm situated in the municipality of St.Philemon, county of Bellecbasse, designated under number thirty-nine-B (39-B) of the fourth range (IV) of the township Mailloux, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies; as the whole is to be found presently with the active and passive servitudes.To be sold at the church door of St-Philemon, county of Bellecbasse, THURSDAY, the FIFTH day of SEPTEMBER, 1957, at HALF PAST TWO o'clock in the afternoon (2.30 o'clock P.M.).CHS.OMER BERNIER.Sheriff's Office, Sheriff.Montmagny, July 29, 1957.45502-31-2 MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: ( JEAN PAUL JOLY, de-N° 407340.< J mandeur vs Dame AN-l NETTE LANCE VIN, é-pouse séparée de biens de J.Léon Guilbault, et ce dernier pour autorisé son épouse aux fins des présentes, défenderesse.\"Un certain emplacement situé sur le côté Nord du Boulevard Ste-Rosc, dans la ville cie Ste.Rose, connu et désigné comme faisant partie du lot numéro quarante (P.40) des Plan et Livre de renvoi officiel du Village Incorporé de Ste.Rose, comté de Laval, comprenant tout le terrain contenu dans les bornes et limites suivantes, savoir, en front, vers le Sud par le Boulevard Ste.Rose, en arrière à Blanche et Irène Dcmers ou représentants, d'un côté à l'Ouest partie par lot N° 41 sur ledit plan appartenant à Aima Ver-don et partie par l'emplacement de Orner La-plante ou représentants, étant aussi partie dudit lot 40 et de l'autre côté vers l'est partie sur le lot trente-neuf sur ledit plan appartenant à Leopold Foucault et partie par une autre partie dudit lot 40 appartenant à Fortunio Lussier avec maison comprenant magasin, maison privée et théâtre et autres bâtisses y érigées; et le susdit immeuble sujet à servitudes actives et passives suivant acte de conventions enregistré à Laval, sous le N° 61584.\" Pour être vendu, à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de Sainte-Rose, comté de Laval, le CINQUIÈME jour de SEPTEMBRE 1957, à ONZE heures du matin.I e S!ic*rif Bureau du Shérif, CAISSE & HURTEAU.Montréal, 30 juillet 1957.45520-31 -2-o MONTREAL Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit : f TEAN PAUL JOLY, plain.No.407340.< j tiff, vs Dame AN MX l TE LANGEVIN, wife separate as to property of J.Léon Guilbault.and the latter to authorize his wife for these presents, defendant: \"A certain emplacement situated on the north side of Boulevard Ste-Rose, in the town of Ste-Rose, known and designated as forming part of lot number forty (Pt.40) on the official plan and in the book of reference of the Village Incorporé de Ste.Rose, county of Laval, comprising all the land contained in the following boundaries and limits, to wit, in front, on the south, by the Ste-Rose Boulevard, in rear, by Blanche and Irène Deniers or representatives, on one side on the West, partly by lot No.41 on the said plan belonging to Alma Verdon and partly by the emplacement of Omer Laplante or representatives, being also part of the said lot 40 and on the other side on the East, partly on lot thirty-nine on the said plan belonging to Leopold Foucault, and partly by another part of the said lot 40 belonging to Fortunio Luissier, with house comprising store, private house and theatre and other buildings thereon erected; and the above said immoveable subject to the active and passive servitudes, according to registered conventional deed at Laval, under No.61584.\" To be sold at the parochial church door of the parish of Sainte-Rose, countv of Laval, SEPTEMBER FIFTH, 1957, at ELEVEN o'clock in the forenoon.CAISSE & HURTEAU, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, July 30, 1957.45520-31-2 QUÉBEC Fieri Facias Québec, à savoir: /TEAN PAUL MARCOUX, N° 87,698.
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.