Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 11 avril 1959, samedi 11 (no 15)
[" Tome 91, N° 15 1577 Vol.91, No.15 \t\t \t\t \t\t1 \t\t \t\tX Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Quebec, samedi 11 avril 1959 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, April 11th, 1959 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., arc strictly payable in advance.(i.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 1578 GAZETTE OFFIt TELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 avril 1959, Tome 91, N° 15 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas.l'ultime délai expire à midi, le mercredi.\u2022 Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus.l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces: Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (1-1 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Alionnement : S7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que «le notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502 \u2014 l-52-o Lettres patentes (P.G.10746-59) Acron Invest men I Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix février 1959, constituant en corporation: Yvonne Bélanger, Dorothea Calver, et Sylvia Vineberg, toutes secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Acron Investment Corp.\", avec un capital total de §3,000, divisé en 300 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 50241 P.PREENTTE.receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.Tn the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's IVinter is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 line* per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: 87 per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th.1940.41502\u2014l-52-o Letters Patent (A.G.10746-59) Acron Investment Corp.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies* Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing dale the tenth day of February, 1959, incorporating: Yvonne Bélanger, Dorothea Calver and Sylvia Vincberg, all secretaries, filles majeures, of Moid real, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Acron Investment Corp.\", with a total capital slock of $3,000, divided into 300 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of February, 1959.P.FRENETTE, 5024l-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April llth, 1959.Vol.91.No.16 1579 (P.G.10791-59) Adanac Aluminum Ltd.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de lu Loi des compagnies de Québec, il u été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize février 1959, constituant en corporation: Luc Geoffroy, de Chambly, Robert Dulude, de Dorion, et Robert-Y.Lanthier, «le Ste-Rose, tous avocuts, pour les objets suivants: Fabriquer, acheter, vendre, importer, exporter et «-n général, faire le commerce d'aluminium et produits «Tiédie, et tous autres produits semblables sous le nom de \"Adanac Aluminum Ltd.\", avec un capital-actions divisé en 1,000 actions sans valeur nominale ou au pair et 1,000 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $10 chacune et le montant avec lequel la compagnie commencera ses activités sera de $0,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 50241 1».FRENETTE.(P.G.10943-59) Algonquin Chemicals Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Ix)i des compagnies de Québec, il a été acconlé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lcttrse patentes, en date du dix-huit février 1959, constituant en corporation: Léo Rolotcn, gérant de ventes, Raymond Cloutier, vendeur, et Morris Schwartz, chimiste, tous de Montréal, pour les ojbets suivants: Fabriquer et faire le commerce et le négoce de nettoyeurs, peintures, détersifs, savons, cires, produits «le nettoyage, substances chimiques et produits chimiques et de toutes sortes ainsi «pie les produits s'y rapportant, sous le nom de \"Algonquin Chemicals Ltd.\", avec un capital total «le $50.000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 250 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le dix-huit février 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.(P.G.10898-59) A.L.M.Supply Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec des lettres patentes, en date du dix-huit février 1959.constituant en corporation: Marcel Trudeau, Gérard Beaupré, avocats, et Marthe Blouin, secrétaire, célibataire majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Commerce «le matériaux de construction, sous le nom de \"A.L.M.Supply Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 2.000 actions de S10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Mont-réal-Nord, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.50241-e P.FRENETTE.(A.G.10791-59) Adanac Aluminum Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date tlx; thirteenth day of February, 1959, incorporating: Luc Geoffroy, of Chambly, Robert Dulude, of Dorion, and Robert-Y, Lanthier, of Ste.Rose, all lawyers, for the following purposes: To manufacture, buy, sell, import, export and generally deal in aluminum and the by-products thereof, or all other similar products, under the name of \"Adanac Aluminum Ltd.\", with a capital stock divided into 1,000 shares of no nominal or par value ami 1,000 preferred shares of a par value of 810 each, and the amount with which the companv will commence its operations will be $6,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial «lislrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth f $100 each and 200 pre ferreel shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the oflice of the' Attorney General, lids twelfth dav eif February, 1959.P.FRENETTE, 502-1 l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10731-59) Davmar Investment Corp.Notice is hereby given thai under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of February.1059.incorporating: Manuel Shacter, of Dorval.Stanley Taviss and William Levitt, «>f Montreal, all advocates, feu- the following purposes: 1586 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 avril 1959, Tome 91, A'° 15 Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Davmar Investment Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune et 39,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.(P.C.10622-59) D.& E.Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six février 1959, constituant en corporation: Louis H.Rohrlick, avocat et conseil en loi de la Reine, Benjamin .1.Greenberg, étudiant et Mary Watt, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, |M>ur les objets suivants: Effectuer des placements de toutes sortes, sous le nom de \"D.& E.Investments Inc.\", avec un capital total de §750,000, divisé en 500 actions privilégiées, catégorie \"A\", d'une valeur au pair de $10 chacune, 1.480 actions privilégiées, catégorie \"B\", d'une valeur au pair de S500 chacune et 50 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 50211 P.FRENETTE.(P.O.10839-59) Delray Investments Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize février 1959, constituant en corporation: Neil Phillips, avocat, Sylvia Vineberg et Yvonne Bélanger, secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Acheter ou autrement acquérir et détenir, posséder, y construire et développer des propriétés immobilières et immeubles à des fins de placements, et agir comme bailleurs et administrateur en ce qui s'y rapporte, sous le nom de \"Delray Investments Limited\", avec un capital total de $10.000.divisé en 200 actions ordinaires de $10 chacune et 3,800 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 50241 p.FRENETTE.(P.G.10729-59) Diploma Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze février 1959, constituant en corporation: I/x>nard Liverman, Julius Briskin et Arthur Yanof.sky, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Davmar Investment Corp.\".with a total capital stock of $40,-000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 39,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of February, 1959.P.FRENETTE, 5021 l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10022-59) D.& E.Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec\" Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of February, 1959, incorporating: Louis H.Rohrlick, advocate and Queen's Counsel, Benjamin J.Greenl>erg, student, and Mary Watt, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To make investments of all kinds, under the name of \"D.& E.Investments Inc.\", with a total capital stock of $750.000, divided into 500 Class \"A\" preferred shares of a par value of $10 each, 1,480 Class \"B\" preferred shares of a par value of $500 each and 50 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of February, 1959.P.FRENETTE, 50241 -o Acting Deputy Attorney General.(a.g.10839-59) Delray Investments Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quel>ec Companies' Act, letters i>atent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of February, 1959, incorporating: Neil Phillips, advocate, Sylvia Vineberg, and Yvonne Bélanger, secretaries, filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: To purchase or otherwise acquire and to hold, own, build on, and develop immoveable proj>erty and real estate for investment purposes, and to act as lessors and administrators in connection therewith, under the name of \"Delray Investments Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $10 each and 3,800 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of February.1959.P.FRENETTE, 50241-o Acting Deputy Attorney General.(a.g.10729-59) Diploma Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of \" the Quebec Companies' Act, letters patent have been isssued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of February.1959, incorporating: Leonard Liverihan, Julius Briskin and Arthur Yanof.sky, all advocates, of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 11th, 1969, Vol.91, No.16 1587 Exercer le commerce (l'une compagnie de terrains, amelioration et gestion, sous le nom de \"Diploma Investments Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le douze février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.50241 P.FRENETTE.(P.O.11013-59) Domaine 8t.Eustache Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre février 1959.constituant en corporation: John Maria C'eriiu.conseil en loi de la Reine, de Montréal, Robert Lcarmont Jamieson.de Pointe-Claire, et Raymond Michael Harold Bennett, de Verdun, tous avocats, pour les objets suivants: Commerce d'immeubles et de compagnie de construction, sous le nom de \"Domaine St.Eustache Ltée\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 50241-O .P.FRENETTE.(P.G.10747-59) Druna Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix février 1959, constituant en corporation: Yvonne Bélanger, Dorothea Calver et Sylvia Vineberg, toutes secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Acheter ou autrement acquérir et détenir, pos-.séder, y construire et développer des propriétés immobilières et immeubles à des fins de placements, et agir comme bailleurs et administrateurs en ce qui s'y rapport sous le* nom de \"Druna Investment Corp.\", avec un capital total de $3,000, divisé en 300 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire, de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.50241 P.FRENETTE.(P.G.10919-59) Ecole de Tissage du Tapis d'Orient Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit février 1959, constituant en corporation: Guy Letarte, de Ste-Foy, André Trotier, de Charlesbourg, tous deux avocats, et Claudette Thibault, secrétaire, de Québec, pour les objets suivants: To carry on the business of a land, improvement and management company, under the name of \"Diploma Investments Inc.\", with a total capital stock of $-10,000, divided into 3,500 preferred shares of a par value of $10 each and 500 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of February, 1959.P.FRENETTE, 5024l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11043-59) Domaine St.Eustache Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of February.1959, incorporating: John Maria Cerini, Queen's Counsel, of Montreal, Robert Learmont Jamieson, of Pointe-Claire, and Raymond Michael Harold Bennett, of Verdun, all advocates, for the following purposes: To carry on a business dealing in immoveables and as a building company under the name of \"Domaine St.Eustache Ltée\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth dav of February.1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10747-59) Druna Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of February, 1959, incorporating: Yvonne Bélanger, Dorothea Calver ami Sylvia Vineberg, all secretaries, filles majeures, of Montreal, for the following purposes: To purchase or otherwise acquire and to hold, own, build on, and develop immoveable property and real estate for investment purposes, and to act as lessors and administrators in connection therewith, under the name of \"Druna Investment Corp.\", with a total capital stock of $3,000, divided into 300 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the oflice of the Attorney General, this tenth dav of February.1959.P.FRENETTE, 50241-o Acting Deputy Attorney General.I A.G.10919-59) École de Tissage du Tapis d'Orient Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of February.1959.incorporating: Guy Ix>-tarte, of Ste-Foy, André Trotier, of Charlesbourg, both advocates, and Claudette Thibault, secretary, of Quebec, for the following purposes: 1588 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec 11 avril 1959, Tome 91.N° lu Diriger une école «le tissage et enseigner le métier de tisseur, sous le nom de \"Ecole de Tissage du Tapis d'Orient Inc.\", avec un capital total de §49,000, divisé en 1.000 actions communes de §10 chacune et en 3.900 actions privilégiées de §10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 475, rue Richelieu, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau «lu Procureur général.I«-dix-huit février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241-O P.FRENETTE.(P.g.14838-58) E.IL Desmarais Incorporé Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept février 1959, constituant en corporation: Eilgar-Hildègc Désunirais, ajusteur, du Cap-de-la-Madeleine, Albert Carroll, ajusteur, et Simone Gagnon Carroll, ménagère, épouse séparée de biens dudit Albert Carroll, et dûment autorisée par lui aux fins «les présentes, tous deux de St-Louis-de-France, comté de Champlain, pour les objets suivants: Investigation, évaluation et ajustement de réclamation d'assurances, sous le nom «le \"E.H.Desmarais Incorporé\", avec un capital total de §30,000, divisé en 300 actions de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 304.rue rue des Forges, Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 5024l-o P.FRENETTE.(P.g.10732-59) Erta Realties Ltd.Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie de la \\m\\ des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenaut-gouverncur de la province «le Qué'bec des lettres patentes, en date «lu douze février 1959.constituant en corporation: Samuel H.Shriar, avocat, de St-Laurcnt, Max Polak, étudiant en droit, Mollie Schwartz, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, et Murray B.Spiegel, avocat, de Montréal-Ouest, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie «le terrains et de construction, sous le nom «le \"Erta Realties Ltd.\".avec un capital total «le §40.000.divisé en 100 actions ordinaires «le §100 chacune et 300 actions privilégiées de §100 chacune.Ix> siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le douze février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241 1».FRENETTE.(P.G.10929-59) Fabi «S- Savard Ltée Avis est donné qu'en vertu f the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twelfth day of Fcbruray, 1959, incorporating: Samuel H.Shriar, advocate, of St.Laurent, Max Polak.law student, Mollie Schwartz, secretary, spinster of the full age of majority, both of Montreal, and Murray B.Spiegel, advocate, of Montreal West, for the following purposes: To carry on the business of a land and construction company, under the name of \"Erta Realties Ltd.\".with a total capital stock of §40.000.divided into 100 common shares of §100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of February.1959.P.FRENETTE.5024l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10929-59) Fabi & Savard Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of February, 1959, incorporating: Antonio Fabi, business man.Jacques Taschereau, notary.Gisèle Martel, secretary, spinster «»f full age of majority, all three of Quebec, and Edouard QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 11th, 19Ô9, Vol.91, No.15 1589 Edouard Savard; entrepreneur plâtrier, de Québec-Ouest, pour les objets suivants: Commerce de matériaux de construction, sous le nom (Je \"Fabi & Savard Ltée\".avec un capital total de $5,000, divisé en 250 actions communes de SI0 chacune et en 25 actions privilégiées «le S100 chacune.Ix* siège social «le la compagnie sera à Québec, «listricl judiciaire «le Québec.Daté «lu bureau du Procureur général, l«-«lix-huit février 1059.L'Assistant-procureur général suppléant, 5024l-o P.FRENETTE.(P.G.14735-5S.) Gaspé Télévision Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, eu date «lu vingt-trois février 1959.constituant en corporation: Jean-Paul Aucoin, vendeur, Jean-Marc Gendreàu, commis, f $100 each.The head office «>f the company will be at 980 Manrèse Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of February.1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.1087S-59) Gorlex Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February, 1959, incorporating: Milton L.Klein, advocate, Arthur D.Ruby, chartered accountant, and Iown Lanteigne, stenographer, wife separate as to property of Roger Lanteigne, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as real estate agents and brokers for the sale of all kinds «>f property, moveable and immoveable, commercial housing, urban and rural, under the name of \"Gorlex Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February, 1959.P.FRENETTE, 50241-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10684-59) Growth Const ruction Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act', letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the ninth day «>f February.1959.incorporating: E.Michael Berger, advocate.Margaret Johnston, secretary, fille majeure usant «le ses droits, both of Montreal, and Donald Kujan.advocate, of Ville d'Anjou, for the following purposes: To carry on the business of a land ami const ruction company, under the name of ''Growth Construction Co.\".with a total capital stock of §30.000.divided into 200 common shares of $50 each and 2.000 preferred shares of $10 each.The head oflice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of February, 1959.P.FRENETTE, 5021 l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14475-58) Henri Grenier Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty- 1592 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, II avril 1959, Tome 91, N° 15 du vingt-trois février 1950.constituant en corporation: Henri Grenier, épicier.Marguerite Villeneuve, ménagère, épouse contractuellement séparée «le biens dudit Henri Grenier, et dûment autorisée par lui aux fins «les présentes.t Joseph Grenier, ouvrier, tous «le .lompiière, pour les objets suivants: Commerce d'épicerie et «le boucherie, sous le nom «le \"Henri Grenier Limitée\", avec un capital total «le 820.000.divisé en 200 actions communes de 8100 chacune.Le si«*'g«' social de la compagnie sera 385, boulevard «lu Centenaire, Jonquière, district judiciaire «h- Chicoutimi.Daté «lu bureau «lu Pnx-ureur général, le vingt-trois février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241-O I'.FRENETTE.(P.G.10310-50) Hôpital Général de Ville Emard General Hospital Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «h- Québec des lettres patentse, en date du vingt-trois lévrier 1959, cousitutant en corporation sans capital-actions: Dr Robert Lemyre, Dr André Rioux, tous deux médecins, «le Verdun, Dr Jean-Guy Tessier, radiologiste, de Montréal, René Duranleau, avocat et conseil en loi de la Reine, de l'Ile Bigras, et Gaston Bédard, comptable agréé, de Ville St-Pierre, pour les objets suivants: Recevoir, pensionner, prendre soin et ou faire soigner les personnes malades ou infirmes, sous le nom «le \"Hôpital Général de Ville Emard General Hospital\".Le montant auquel sont limites les biens immobiliers que la corporation oeid posséder est (\\v $500,000.Ia: siège social de la corporation sera à Ville Emard, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 5021 l-o P.FRENETTE.(P.G.10347-59) Ihqntal Notre-Dame de Grâce Hospital Avis est donné «pieu vertu «le la troisième partie «le la Loi «les compganies «le Québec, il a été accordé par le Licntcnant-gouvcrneur «le la province de Québec «les lettres patentes, en date «lu vingt-trois lévrier 1959, constituant en corporation sans capital-actions: Dr Roméo de Grand-pré, médecin, «le St-Laureiit.Dr Laurent Sam son, Dr André Cusson, Dr l'ernand Croisetière, médecins, Dr Jean-Maurice Bourque, chirurgien, tous quatre de Montréal, Dr Jean-Paul Du Ruisseau, biologiste, de Pont-Viau, et Gaston Bédard, comptable agréé, de ville Mont-Royal, pour les objets suivant-,: Recevoir, pensionner, prendre soin et ou faire soigner les personnes malades ou infirmes, sous le nom de \"Hôpital Notre-Dame de Grâce Hospital\".Ia; montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est «le $750.000.Le siège social de la corporation sera à Mont-réal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois février 1050.L'Assistant-procureur général suppléant, 50241-O P.FRENETTE.thinl «lay «>f February.1050.inc«>rpornting : Henri Grenier, grocer, Marguerite Villeneuve, housewife, wife contractually separate as to property of the said Henri Grenier, and duly authorized by him for these present purposes, ami Joseph Grenier, workman, all of .lompiière, for the following purposes: To carry on a business dealing in groceries and as butchers, under the name of \"Henri Grenier Limiter\", with a total capital stock of $20,000.divided into 200 common shares of $100 each.The head oflice of the company will be at 385 «lu Centenaire Boulevard, .lompiière, judicial district of ( 'hicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of February, 1050.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(À.G.10340-50) Hôpital General de Ville Emard General Hospital Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the February twenty-third, 1050, to incorporate as a corporation without share capital: Dr.Robert Lemyre, Dr.André Rioux.both physicians, «>f Verdun, Dr.lean-Guy Tessier.radiologist, of Montreal, René Duranleau, advocate and Queen's Counsel, of He Bigras, and Gaston Ré-dard, chartered accountant, of ville St-Pierre, lor the following purposes: To receive, board, take care of and/or see t«) the care of sick or crippled persons, under the name of \"Hôpital Général de Ville Emard General Hospital\".The amount to which the value of the immoveable property which the eorportaion may hold is to be limited, is $500.000.The head office of the corporation will be at Ville Emard, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third day «>f February, 1050.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10347-59) Hôpital Notre-Dame de Grâce Hospital Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor « f the Province of Quebec, bearing date the February twenty-third, 1050.to incorporate as a corporation without share capital : Dr Roinéo «le Granpré, physician, of St-Laurent, Dr.Laurent Samson.Dr.André Cusson, Dr.Fern and Croisetière, physicians, Dr.Jean-Maurice Bourque, surgeon, all four of Montreal.Dr.Jean-Paul Du Ruisseau, biologist, of Pont-Viau, ami Gaston Bédard, chartered accountant, of the town of Mount-Royal, for the following purposes: To receive, boanl.take care of and/or see to the care of sick or crippled persons, under the name of \"Hôpital Notre-Dame de Grâce Hospital\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $750.000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third dav of Februarv.1050.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, Quebec, April 11th, 1969, Vol.91, So.15 1593 (P.G.10639-59) Howard-Ellen Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenarit-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf février 1959, constituant en corporation: Léo Rosentzveig, Stanley Taviss et William Levitt, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et placements, sous le nom de \"Howard-Ellen Holdings Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune, 10,000 actions catégorie \"A\" de $1 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.(P.G.10873-59) Ideal Inside Door Industries Ltd.Avis est donné qif'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept février 1959, constituant en corporation: Pierre Bourque, Raymond Rodrigue et Luc Doyon, tous industriels, de Notre-Damc-des-Pins, pour les objets suivants: Industrie et commerce de portes, fenêtres et autres ouvertures, sous le nom de \"Ideal Inside Door Industries Ltd.\".avec un capital total «le $80,000, divise en 400 actions communes de $100 chacune et en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Notre-Damc-des-Pins, district judiciaire de Bcauec.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241 -o P.FRENETTE.(P.G.10587-59) kareni Holdings Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ia>\\ des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du (piatre février 1059.constituant en corporation: John J.Wasserman, avocat, de Westimuint, Harold S.Freeman, Daniel Morris, avocats, et Dorothy Martel, secrétaire, fille majeure, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Karem Holdings Corp.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le $1 chacune et 3,900 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $10 chacune.Ia; siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le quatre février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.(A.G.10639-59) Howard-EUcn Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of February, 1959, incorporating: Leo Rosentzveig, Stanley Taviss and Willam Levitt, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a realty and investment company, under the name of \"Howard-Ellen Holdings Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each, 10,000 Class \"A\" shares of $1 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of February.1959.P.FRENETTE, 5024l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10873-59) Ideal Inside Door Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, beat ing date the seventeenth day of February, 1959, incorporating: Pierre Bourque, Raymond Rodrigue and Luc Doyon, all industrialists, of Notre-Dame-des-Pins, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing with doors, windows and other openings, under the name of \"Ideal Inside Door Industries Ltd.\", with a total capital stock «>f $80.000, divided into 400 common shares of $100 each and into 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Notre-Dame-des-Pins, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February, 1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A:G.105S7-59) Karetu Holdings Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «if Quebec, bearing date the fourth day of February.1959, incorporating: John J.Wasserman.advocate, of Westimuint, Harold S.Freeman, Daniel Morris, advocates, and Dorothy Martel, secretary, spinster of the full age of majority, all three «>f Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, development and construction company, under the name of \"Karein Holdings Corp.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 1.000 common shares of a par value «>f $1 each and 3.900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of February.1959.P.FRENETTE, 50241-O Acting Deputy Attorney General. 1594\" GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, 11 avril 1909, Tome 91, N° lù (P.G.10595-59) Kores Mfg.Corporation Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres pateides, en «late «lu quatre février 1959.constituant en corporation: Antoine Paré, «lu village de St-André Est, Jean Thomas Vien, de Préville, tous deux avocats, et Evariste Lavoie, comptable, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fabricants et marchands «le toutes sortes de patrons et encres, papiers carbone et rubans «le dactylographes, sous le nom «le \"Kores Mfg.Corporation\", avec un capital total «le $50,000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le quatre février 1959.X'Assistant-procureur général suppléant; 50241 _ P.FRENETTE.(P.G.10800-59) Lacombe Transport Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept février 1959, constituant en corporation: Elie Lacombe, entrepreneur, Béatrice Lacombe, ménagère, épouse séparée de biens dudit Elie Lacombe, tous deux de ville LaSalle, et Gisèle Lauzon, secrétaire, de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des entreprises de camionnage et généralement faire le transport de marchandises de toutes sortes, sous le nom de \"Lacombe Transport Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 160, rue Centrale, ville LaSalle, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 5024l-o P.FRENETTE.(P.G.10910-59) Lakesbore Caterers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec des lettres patentes, en «late du dix-huit février 1959, constituant en corporation: Max Slapack, avocat, «le la ville Côte St-Luc, Gregory Oharlap, Arthur Shulman, avocats, et Sylvia Teitlebaum, secrétaire, fille majeure, tous trois «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurant, cafeteria, friandises, fontaine à soda, comptoir-lunch, de rafraîchissements, de tabac, de journaux et de fruits, traiteurs «le salles à manger, pourvoyeurs licenciés, hotelier, tavernier et aubergiste, sous le nom de \"Lakesbore Caterers Ltd.\", avec un capital total «le $11,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Valois, district judiciaire de Montreal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le dix-bnit février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.(A.G.10595-59) Kores Mfg.Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the fourth day of February.1959, incorporating: Antoine Paré, of the village of St.Andrews East, Jean-Thomas Vien.of Préville, both lawyers, and Evariste Lavoie.accountant, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturers and dealers in all kinds of stencils and inks, carbon papers and typewriter ribbons, under the name of \"Kores Mfg.Corporation\", with a total capita] stock oJ $50.000, divided into 500 common shares of $100 each.The head oflice of the company will be at Mont real, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of February, 1959.P.FRENETTE, 5024l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10866-59) Lacombe Transport Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February 1959, incorporating: Elie Lacombe, contractor, Béatrice Lacombe, housewife, wife separate as to property of the said Elie Lacombe, both of the town of LaSalle, and Gisèle Lauzon, secretary, of Montreal, for the following purposes: s Operate a trucking business and generally forw ad goods of all kinds, under the name of \"Lacombe Transport Inc.\", with a total capital stock of S40,000, divided into 4.000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 100 Central Street, town of LaSalle, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February, 1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10910-59) Lakesbore Caterers Ltd., Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «laie the eighteenth day of February, 1959.incorporating: Max Slapack, advocate, of the town of Côte St.Luc, Gregory Charlap.Arthur Shulman, advocates, ami Sylvia Teitlebaum.secretary, spinster of the full age of majority, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of restaurant, cafeteria, delicatessen, sodafoutain.lunch counter, refreshment, tobacco, news and fruit stands, din-ingroom caterers, licensed victuallers, hotel, tavern and inn keeper, under the name of \"Lake-shore Caterers Ltd.\", with a total capital stock of $11,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Valois, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth dav of February, 1959.P.FRENETTE, 50241-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec.April 11th, 1959, Vol.91.No.15 1595 (P.G.14576-58) I-amart Development Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf février 1959.constituant en corporation: l^ouis-M.Benjamin, avocat, de Montréal, Isidore Morgulis, comptable, et Catherine .Skinner Spichnan, secrétaire, épouse séparée de biens de David Spiclman, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous deux de VYestmount, pour les objets suivants: Acheter et vendre des terrains et immeubles de toutes sortes, sous le nom de \"Lamart Development Co.Ltd.\", avec un capital total de $25,000, divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 57 ouest, rue St-Jacques, suite 515, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le neuf février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.(P.G.11003-59) La Plomberie André Inc.André Plumbing & Heating Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec des lettres patentes, en date du vingt-six février 1959.constituant en corporation: Claudc-R.Vallerand, de Repentigny, Claude Tellier, «le Montréal, et Pierre Bernier.de Duvernay, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneur en plomberie, chauffage et réfrigération, sous le nom «le \"La Plomberie André Inc.\u2014 André Plumbing & Heating Inc.\", avec un capital total de $10.000.divisé en 10.000 actions de $1 chacune.I.C siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt -six février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, .50241-.» P.FRENETTE.(P.G.10913-59) Larkwood Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie f \"Ix> Club «le Golf «le Cap-Rouge Inc.\u2014 The Cap-Rouge Golf Club Inc.\", with a total capital stock of §100.000, divided into .500 shares of 8200 each.The head oflice of the company will be at Saint-Félix-du-Cap-Rôuge, judicial «listrict of Quebec.Dated at the office «>f the Attorney General, this fourth dav of March.1959.P.FRENETTE, 50211 Acting Deputy Attorney General.(P.G.10973-59) I.c Conseil du Bien-Etre île Valleyfield The Valleyfield Welfare Council Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie «le la D>i «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec «les lettres patentes, en date «lu vingt février 1959, constituant en corporation sans capital-actions: Mgr Jean-Denis Cadièux, prêtre délégué «le l'Ordinaire, Gérard Bélanger, courtier, Paul Charette.industriel, Adrien Cho-lette, agent «l'affairés, Dr Armand Clairmont, dentiste, Clifford Foley, gérant.Maurice I^ipoin-te, marchand, Albert Leblanc, avocat.Eric Ix-duc, optométriste, Jean-Claude Lefebvre, journaliste, et Léo-GcorgCS Perron, entrepreneur, tons de Valleyfield, pour les objets suivants: (A.G.10973-59) Le Conseil du Bien-Ètre de Valleyfield The Valleyfield Welfare Council Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twentieth day of February 1959, to incorporate as a corporation without share capital: Mgr.Jean-Denis Cadieux, priest, delegate of the ordinary, Gérard Bélanger, broker.Paul Charette, industrialist, Adrien Cholette.business agent.Dr.Armand Clairmont.dentist.Clifford Foley, manager.Maurice Lapointe, merchant, Albert Leblanc, advocate, Erli Leduc, optometrist, Jean-Clamle Lefebvre, journalist, and Léo-Georges Perron, contractor, all of Valleyfield, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 11th, 1969, Vol.91, No.15 1597 Grouper, orienter, diriger les oeuvres d'assistance et les sociétés de bienfaisance sociale dans les limites du diocèse de Valleyfield, soit dans les comtés provinciaux de Beauharnois, Château-guay, Huntingdon.Vaudreuil-Soulanges, sous le nom de \"Ix; Conseil du Bien-Etre.de Valleyfield \u2014 Tlic Valleyfield Welfare Council\".Ix.* montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $100.000.Le siège social de la corporation sera à Sala-berry-de-Valleyfield, district judiciaire de Beau-harnois.Daté du bureau du Procureur général, le vingt février 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 5024l-o P.FRENETTE.(P.G.10942-59) Les Associés du Centre Audio-Visuel Inc.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date «lu dix-huit février 1959, constituant en corporation: Lucien Chevrette, Robert Trépanier.adjoints administratifs, et Fabien Rivard, superviseur, tous des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Acheter et vendre tout matériel pouvant servir à la reproduction ou à la trasmission d'images et de sons et faire toutes les choses qui sont incidentes ou qui conduisent à la réalisation des objets précités, sous le nom de \"Les Associés du Centre Audio-Visuel Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions communes d'une valeur au pair ou nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 452, rue des Forges, Trois-Rivières, «listrict judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 5024l-o P.FRENETTE.(P.G.10920-59) Les Ateliers de Réparation et de Nettoyage' de Tapis Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit février 1959, constituant en corporation: André Trotier, de Charlesbourg, Guy Letar-te, de Stc-Foy, tous deux avocats, et Claudette Thibault, secrétaire, de Québec, pour les objets suivants: Commerce de tapis, prélarts et autres matériaux servant à recouvrir les planchers, y compris la réparation et le nettoyage de tapis, sous le nom de \"Les Ateliers de Réparation et de Nettoyage de Tapis Inc.\".avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 475, rue Richelieu, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 5024l-o P.FRENETTE.To group together, guide and direct works of relief and social welfare societies within the boundaries of the diocese of Valleyfield, that is in the Provincial Counties of Beauharnois, Chft-teauguay, Huntingdon, Vaudreuil-Soulanges, under the name of \"Ix> Conseil du Rien-Être de Valleyfield \u2014 The Valleyfield Welfare Council\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at Salaberry-de-Valleyfield, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of February 1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10942-59) Les Associés du Centre Audio-Visuel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of February, 1959, incorporaing: Lucien Chevrette, Robert Trépanier, joint executives, and Fabien Rivard, supervisor, all of Trois-Rivières.for the following purposes: To buy and sell any materials which may serve in reproducing or transmitting pictures and sounds, accomplish all things which are incidental or conducive to the realization of the aforesaid objects, under the name of \"Les Associés dp ('entre Audio-Visuel Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of a nominal or par value of $10 each.The head office of the company will be at 452 des Forges Street, Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of February, 1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney Genera).(A.G.10920-59) Les Ateliers de Réparation et de Nettoyage de Tapis Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of February, 1959, incorporating: André Trotier, of Charlesbourg, Guy Letartc, of St.I'oy.bol h advocates, and Claudette Thibault, secretary, of Quebec, for the following purposes: Deal in carpets, oilcloth and other floor coverings including the repairing and cleaning of carpets, under (the name of \"Les Ateliers dc Réparation et de Nettoyage de Tapis Inc.\", with a total capital slock of $5.000.divided into 500 shares of $10 each.The head office of the company will be at 475 Richelieu Street.Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of February.1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General. 1598 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec 11 avril 1959, Tome 91, N° 16 (P.g.13844-58) Les Kntreprises Asselin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six février 1959, constituant, en corporation: Hector Asselin, ingénieur professionnel.Janine Étliier Asselin, ménagère, épouse contract uellcmcnt séparée de biens dudit Hector Asselin, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux d'Outrcmont, et Alfred-E.Asselin, rentier, de Ville Mont-Royal, pour les objets suivants : Commerce d'immeubles et de compagnie de construction, sous le nom «le \"Les Entreprises Asselin Inc.\", avec un capital total de §50,000, divisé en 10.000 actions «le $5 chacune.Ix* siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt-six février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 50241-o P.FRENETTE.(P.g.10837-59) Les Entreprises Greenland Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la I/oi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en «late du .seize février 1959, constituant en corporation: Joffre Bacque, agent d'immeubles.Albert Ther-rien, entrepreneur, et Claude Therrien, commis, .tous de Québec, |>our les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'en-trepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Les Entreprises Greenland Inc.\", avec un capital total de 830.000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 100 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Charlesbourg, «listrict judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le seize février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 5024l-o P.FRENETTE.(P.g.10473-59) Mademoiselle Sboppe Inf Out remount, and Alfred-E.Asselin, annuitant, of the Town t>f Mount-Royal, for the following purposes: To carry on a business dealing in immoveables and as a construction company uiuler the name of \"Les Entreprises Asselin Inc.\", with a total capital stock «.f $50.000, divided into 10,000 shares of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth dav of February, 1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10837-59) Les Entreprises Greenland Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of February, 1959, incorporating: Joffre Bacque, real estate agent, Albert Therrien, contractor, ami (Maude Therrien, clerk, all of Quebec, for the following purposes: To carry on a business as builders and general building contractors uiuler the name of \"Les Entreprises Greenland Inc.\", with a total capital stock of $30,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 100 preferred shares of $100 each.The heatl office «>f the company will be at Charlesbourg, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of February, 1959.P.FRENETTE, .50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10473-59) Mademoiselle Shoppc Inc.Notice is hereby given that under \"Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth «lay of February 1959, incorporating: Jean-Maurice Daigle, merchant, Fatima Zahra.merchant, wife separate as to property of the sai«l Jean-Maurice Daigle, and «luly authorize*! by him for the purposes therein, and Claude Noi-scux, advocate, all of Cowansvillc, for the following purposes: Deal in wearing apparel, uiuler the name of \"Mademoiselle Shoppe Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 300 common shares «>f $100 each ami 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Cowansvillc, judicial «listrict of Bef March, 1959, incorporating: Bernard Léveillé, André Harvey and Jean-Louis Voisine, both secretaries, of Alma, for the following purposes: To carry on a business dealing in clothing, shoes, knitwear, textiles and jewels, under the name of \"Marcelle L.Inc.\".with a total capital stock of $20.000.divided into 200 shares «>f $100 each.The head office «)f the company will be at Alma, Lake St.John, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of March, 1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General. 1600 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 avril 1959, Tome 91, N° 15 (P.G.14273-68) Marcel Watier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit février 1959.constituant en corporation: René Beaudry, de Verdun.Louis-Claude Trudel et Joseph Vallières, «le Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Commerce d'épicerie, sous le nom de \"Marcel Watier Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saintc-Anne-de-Bellevue.district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant.5024l-o P.FRENETTE.(P.G.10740-59) Melling Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en «late «lu dix février 1959, constituant en corporation: Irwin Gliserman, Moe Ackman, avocats, Doreen Weldon, et Annette Katz, secrétaires, filles majeures, tous «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie d'immeubles et construction, sous le nom «le \"Melling Co.Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 300 actions ordinaires de $10 chacune et 700 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le dix février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.(P.G.14143-58) Montreal Dog Obedience Training Club Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du douze février 1959.constituant en corporation sans capital actions: George William Millar, administrateur «le ville Mont-Royal.Janet Ruth Jack Yellan, ménagère, épouse de George Thomas Yelland, et dûment autorisée par ce dernier, de Montréal, et John G.Harper, administrateur, de Westmount, pour les objets suivants: Etablir, entretenir et diriger un club d'entraînement consistant à faire obéir les chiens sous le nom de \"Montreal Dog Obedience Training Club Inc.\".Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder est $500.Ix* siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, -50241 P.FRENETTE.(A.G.14273-58) Marcel Watier Inc., Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of February.1959, incorporating: René Beaudry, of Verdun, Louis-Claude Trudel and Joseph Vallières, of Montreal, all advocates, for the following purposes: Deal in groceries, under the name of \"Marcel Watier Inc.\".with a total capital stock of $40,-000.divided into 500 common shares of a par value of $10 each an«l 350 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Sainte-Anne-de-Bellevue, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth dav of February, 1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10740-59) Melling Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of February, 1959.incorporating: Irwin Gliserman, Moe Ackman, a«lvocates, Doreen Weldon and Annette Katz, secretaries, spinsters of full age of majority, all of Montreal, for the^ following purposes: To carry on the business of a realty and con-struction company, under the name t)f \"Melling Co.Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 300 common shares of $10 each and 700 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General,, this tenth day of February, 1959.P.FRENETTE.50241-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14143-58) Montreal Dog Obedience Training Club Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of February, 1959, to incorporate as a corporation without share capital: George William Millar, executive, «>f the town of Mount Royal, Janet Ruth Jack Yelland, housewife, wife of George Thomas Yelland.and duly authorized by him, of Montreal, ami John G.Harper, exe-cutive, of Westmount, for the following purposes: To establish.maintain and conduct a Dog Obedience Training Club, uiuler the name of \"Montréal Dog Obedience Training Club Inc.\".The amount of which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $500.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General» this twelfth date of February.1959.\" P.FRENETTE, 5024l-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec April 11th, 1969, Vol.91.No.15 1601 (P.G.10250-59) Nor-Ficld Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de lu Loi des compagnies de Québec, il a été accordé pur le Lieutenant-gouverneur de lu province de Québec des lettres putentes, en dute du vingt-sept janvier 1959, constituant en corj>o-ration: Samuel Leon Mendelsohn, conseil en loi de la Reine, de Westmount, Léo Rosentzveig, William Levitt, tous deux de Montréal, et Manuel Shacter, de Dorval, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Nor-Ficld Development Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 3,000 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept janvier 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.(P.G.10232-59) Norvil Construction Ltée Norvil Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en «late du vingt-trois février 1959, constituant en corporation: Gahriclle La haie, secrétaire, fille majeure.Georges-A.Pouliot, Luc Mercure.Jacques LeBel et Bertrand Prud'homme, tous quatre avocats, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie «le construction, sous le nom de \"Norvil Construction Ltée - - Norvil Construction Ltd.\", avec un capital total de $50.000, divisé en 300 actions communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à L'Abord-à-Plouffe, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 5024l-o I».FRENETTE.(P.G.13972-58) O.Fontaine Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Ix>i «les compagnies «le Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date du trois décembre I95S, constituant en corporation: Robert Hamel, de M«>ntr«\\'il-Nor«l, Jean-Marie Brassard et Jean Brûlé, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de construction, sous le nom de \"O.Fontaine Construction Inc.\".avec un capital total de $10O:000.divisé en 800 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 8945.rue Lajeunesse, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le trois décembre 1958.L'Assistant-procurcur général suppléant, 5024l-o P.FRENETTE.(A.G.10250-59) Nor-Field Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-seventh day of January, 1959, incorporating: Sumuel Leon Mendelsohn.Queen's Counsel, of Westmount, Ix;o Rosentzveig, Willium Levitt, both of Montreal, and Manuel Shacter, of Dorval, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a land, development and construction company,'under the name of \"Nor-Fiehl Development Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of January, 1959.P.FRENETTE, 50241 -o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10232-59) Norvil Construction Ltée Norvil Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-third day of February, 1959.incorporating: Gabrielle Lahaie.secretary, fille majeure, Georges-A.Pouliot, Luc Mercure, Jacques LeBei and Bertrand Prud'homme, all four advocates, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a construction company, under the name of \"Norvil Construction Ltée \u2014 Norvil Construction Ltd.\", with a total capital stock of $50.000.divided into 300 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at L'Abord-à-Plouffe.judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third day of February, 1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13972-58) O.Fontaine Construction Inc.Notice is hereby given that uiuler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date tin- third day of December.1958.incorporating: Robert Hamel, of Montreal-North, Jean-Marie Brassard and Jean Brule, of Moid real, all advocates, for the following purposes: To carry on business as a construction company, under the name «>f \"0.Fontaine Construction Inc.\", with a total capital stock of $100.000.divided into 800 common shares of a par value «>f $100 each and 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company ill be at 8945 Lajeunesse Street.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day «>f December, 1958.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General. 1002 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.11 avril 1959, Tome 91, N° 15 (P.G.10847-59) Omicron Real i y Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date \u2022 lu sei/e février 1959, constituant en corporation: Samuel David Iludcnko, conseil en loi de la Reine.Clarence Reuben Gross, tous deux avocats, et Sarah Miller, sténographe, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie d'immeubles, sous le nom «h- \"Omicron Realty Corp.\", avec »m capital total «le $3,000, divisé en 3.000 actions de $1 chacune.Ix* siège social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire f a real estate company, under the name of \"P-A-S Associates Inc.\", with a total capital stock of $10.000, divided into 1.000 common shares of a par value of $1 each and 90 preferred shares of a par value «>f $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of February.1059.P.FRENETTE, 50241 -o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10625-59) Raman Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of February.1959.incorporating: Samuel ('hait.Maxwell Shenkcr.advocates, and John Hamilton, secretary, all of Montreal, for the following purposes: To act as an investment corporation, under the name of \"Raman Investment Corporation\", with a total capital stock of $40.000.divided into 4.000 common shares of $1 each and 30.000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at 5105 Sherbrooke Street West, Suite 301.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the oflice of the Attorney General, this ninth day of February.1959.P.FRENETTE.5024l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10520-59) Rami Construction Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 1604 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 avril 1959, Tome 91, N° 16 «'\u2022té accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec «les lettres patentes, en date «lu trente janvier 1959, constituant en corporation: Harold S.Freeman.Daniel Morris, tous deux de Montréal, et John J.Wasserman, «le Westmount, tous avocats, pour les objets suivants: KxertxT le commerce d'une compagnie de construction, sous le nom «le \"Rami Construction Corp.\", avec un capital total de §100,000.divisé en 1,000 actions ordinaires «l'une valeur au pair de §1 chacune et 9,900 actions privilégiées «l'une valeur au pair de §10 chacune.Ix?siège social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Mont irai.Daté «lu bureau du Procureur général, le trente janvier 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.(P.G.10518-59) Renaissance Development Corporation Avis est donné «pi'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutcmint-gouvcrneur «le lu province de Québec des lettres patentes, en date du trente janvier 1959, constituant en corp«)ra-tion: Arthur Yanofsky, Leonard Liverman, et Julius Briskin, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie «le terrains, développement et construction, sous le nom de \"Renaissance Development Corporation\", avec un capital total de §9,000, «livisé en 60 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $50 chacune et 120 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $50 chacune.Ix?siège social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente janvier 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.(P.G; 10745-59) S.B.Reallies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix février 1959.constituant en corporation: Irwin Gliserman, Moe Ackman, avocats, et Annette Katz, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'agents d'immeubles et courtiers, sous le nom de \"S.B.Realties Ltd.\", avec un capital total «le $10.000, divisé en .300 actions ordinaires de $10 chacune et 700 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le dix février 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 50211 p.FRENETTE.(P.G.10807-59) Shamross Realty Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize février 1959, constituant en corporation: Gérard Hébert, conseil en loi de la Reine.Ed- beén issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth «lay of January, 1959, incorporating: Harold S.Freeman, Daniel Morris, both of Montreal, and John J.Wasserman, of Westmount, all advocates., for the following purposes: To carry, on the business of a construction company, uiuler the name of \"Rami Construction Corp.\".with a total capital stock of $100,-000.divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each ami 9,900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth dav of January, 1959.P.FRENETTE, 50241-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10518-59) Renaissance Development Corporation Notice is hereby given that under Part I «>f the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, bearing date the thirtieth day of January, 1959, incorporating: Arthur Yanofsky, Leonard Liverman and Julius Briskin, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, development ami construction company, under the name of \"Renaissance Development Corporation\", with a total capital stock of $9,000.divided into 00 common shares of a par value of $50 each and 120 preferred shares of a par value of $50 each.' The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of Januarv, 1959.P.FRENETTE, 50241 -o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10745-59) S.B.Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the tenth day of February, 1959, incorporating: Irwin Gliserman, Moe Ackman, advocates, and Annette Katz, secretary, spinster of full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of real estate agents and brokers, under the name of \"S.B.Realties Ltd.\".with a total capital stock of $10,000, divided into 300 common shares of $10 each and 700 preferred shares of §10 each.The head office of the company will be at Moid real, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of February, 1959.P.FRENETTE, 50241 -o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10807-59) Shamross Realty Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the sixteenth day of February, 1959, incorporating: Gérard Hébert, Queen's Counsel, Edward G.Tannage. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec,-April 11th, 1959, Vol.91, No.to ward G.Tannage, tous deux avocats.Jeannette Desjardins et Marie-Paule Chalifour, sténographes, célibataires et majeures, tous de Montréal, l>our les objets suivants: Diriger et exercer le commerce de constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de \"Shamross Realty Ltd.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1.C00 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.both advocates, Jeannette Des jardins and Marie-Paule Chalifour, stenographers, unmarried and of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To conduct and carry on the business of builders and contractors, under the name of \"Shamross Realty Ltd.\", with a total capital stock of $100.000.divided into 1,000 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the oflice of the Attorney General, this sixteenth dav of February, 1959.P.FRENETTE, 50241-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.14497-58) Shcii ill Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente janvier 1959, constituant en corporation: Mortimer Dolman, Philip Borrow, notaires, et Ellen Anne Hurley, secrétaire, célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, vendre, échanger, louer ou autrement faire le commerce d'immeubles et propriétés immobilières et négocier pour l'achat, la vente, l'échange ou la location d'immeubles et propriétés immobilières, sous le nom de \"Starling Corporation\", avec un capital total de $10,000, divisé en 10,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente janvier 1959.L'Assistant-procurcur généraI suppléant, 50241 P.FRENETTE.(P.G.10597-59) Studio Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du (piatre février 1959, constituant en corporation: Murray Lapin, «le la ville de Hampstead, lake to the other including the Outaouais River as far as Carillon, under the name of \"Société Organisée de Secours Incorporée \u2014 Society^of Organized Safety Incorporated\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at Sainte Anne-de-Bcllevue.judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of February 1959.P.FRENETTE, 50251 Acting Deputy Attorney (General.(A.G.11041-58) Spade (Quebec) Electrical Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing' «late the twenty-third day of February.1959.incorporating: Lovell C.Carroll, Queen's Counsel, of the Town of Mount Royal, Jean-Paul Cardinal, Queen's Counsel, Jacques-P.Dansereau, both of Montreal.Marcel Ixijeunesse, of Westmount, all four advocates, an«l Jeannette Brodeur, secretary, spinster of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a construction ami of an electrical ami electronics company, under the name of \"Spade (Quebec) Electrical Ltd.\", with a total capital stock of $1,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district «>f Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third dav «>f February, 1959.P.FRENETTE, 50241-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10507-59) Starling Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the thirtieth day of January, 1959, incorporation: Mortimer Dolman, Philip Borrow, notaires, and Ellen Anne Hurley, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To buy, sell, exchange, lease or otherwise deal in real estate and immoveable property and to negotiate for the purchase, sale, exchange or lease of real estate and immoveable property, under the name of \"Starling Corporation\", with a total capital stock of $10.000.divided into 10,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth dav of January, 1959.P.FRENETTE, 50241-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10597-59) Studio Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of February, 1959, incorporating: Murray Lapin, of the town of Hampstead, Morris M. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE) Quebec, April 11th, 1959, Vol.91, No.15 1607 Morris M.Weiner, de Montréal, tons deux avocats, et Shirley Muggeridge, secrétaire, fdle majeure, de Verdun, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises fabriquées en tout ou en partie de cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre et sous-produits, animaux, minéraux, pierres précieuses, liqueurs douces, livres et revues périodiques, oeuvres d'art, produits chimiques et de beauté, produits de la terre, de la mer et «le la forêt; exercer le commerce ou le négoce d'instruments de musique et accessoires, disques, enregistrements «le toutes sortes et descriptions y compris le ruban d'enregistrement, appareils «le radio, «le télévision, phonographes.tourne-«lis«pies et sons stéréophoniques, sous le nom de \"Studio Industries Ltd.\", avec un capital total «le $5.000.divisé en 500 actions d'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 132 ouest, rue St-Jacques, chambre 918, Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le «piatre février 1059.L'Assistant-procureur général suppléant.50241 P.FRENETTE.(P.G.11024-59) Sumac Land Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «lés lettres patentes, en «late du vingt-trois février 1959.constituant en corporation: Avram Harold Garmaise, comptable agréé, Philip Borrow, notaire, et Jeanine-L.Fobert, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, et construction, sous le nom de \"Sumac Land Corporation\", avec un capital total «le $10,000, divisé en 1.000 actions «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à 5803 Chemin Côte «les Neiges, chambre 101.Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt-trois février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.(P.G.11026-59) Tamarack Realties Corp.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Ix>i «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois février 1959, constituant en corporation: Avram Harold Garmaise, comptable agréé, Philip Borrown, notaire, et Jeanine-L.Fobert, secrétaire, fille majeure, tous «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et construction, sous le nom «le \"Tamarack Realties Corp.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1.000 actions de S10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 5803 Chemin Côte des Neiges, Chambre 101, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois février 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.Weiner, of Montreal, both advocates, and Shirley Muggeridge, secretary, spinster of the full age of majority, of Verdun, for the following purposes: To deal in all kinds «>f products, articles and merchandise made, in whole or in part, of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by-products, animals, minerals, precious stones, soft drinks, books and periodicals, works of art.chemical and beauty products, land, sea and forest products; to deal in or with musical instruments ami accessories, records, recordings of every kind and description including tape-recordings, radios, phonographs, televisions, record-players and stereophonic sound, under the name of \"Studio Industries Ltd.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 shares of a par value of S10 each.The head office of the company will be at 132 St.James Street West, room 918, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of February, 1959.i\\ FRENETTE, 50241-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11024-59) Sumac Land Corporation Notice is hereby given that un«lcr Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing «late the twenty-third day of February.1959, incorporating: Avram Harold Garmaise, chartered accountant, Philip Borrow, notary, and Jeanine-L.Fobert, Secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Sumac Land Corporation\"', with a total capital stock of SIO.(MK).divided into l.O(X) shares of $10 each.The head office of the company will be at 5S03 Côte «les Neiges Road.Room 101.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third dav of February, 1959.P.FRENETTE, 5024l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11020-59) Tamarack Realties Corp.Notice is hereby given that under l'art I «>f the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing «late the twenty-third day of February, 1959, incorporating: Avram Harold Garmaise, chartered accountant, Philip Borrow, notary, and Jcanine-L.Fobert, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Tamarack Realties Corp.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1.000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 5803 Côte des Neiges Road, Room 101, Montreal, judicial district of Montréal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third day of February.1959.P.FRENETTE, 5024l-o Acting Deputy Attorney General. 1008 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 avril 1959, Tome 91, N° 15 (P.G.10947-59) (A.G.10947-59) The First Armenian Holy Apostolic Church The First Armenian Holy Apostolic Church Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf février 1959.constituant en corporation sans capital-actions: Keropc Rayman.comptable, Kerop Bedoukian, Onnik Kutahlian, Garabed S.Partzigian.marchands, Haig Marka-rian, Yervant Savoyan, vendeurs, Levon Der Assadourain, administretcur, Garabed Moura-dian, réparateur de tapis, tous les huit de Montréal, Serko Boyadjian, bijoutier.Bedros Kaprie-lian.poseur de carpettes, tous deux d'Outremont, Mitchell Chadrjian, administrateur, de la ville de Baie d'Urfée, Agop Pasdermajian, marchand, de Westmount, et Yervant Pasdermajian, marchand, de ville Mont-Royal, pour les objets suivants: Constituer, les requérants et les personnes qui peuvent dorénavant devenir membres de la corporation, une corporation ecclésiastique, ayant l'autorité et le pouvoir d'exercer tous les droits appartenant aux corporations ecclésiastiques comportant la succession perpétuelle et le droit de poursuivre et celui d'être poursuivi «levant les cours de la province de Québec et alileurs, sous le nom de \"The First Armenian Holy Apostolic Church\".Iaï montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière (pie la corporation peut posséder est $250.000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf février 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 50241 P.FRENETTE.Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of February, 1959, to incorporate as a corporation without share capital: Kerope Bayman, accountant, Kerop Bedoukian, Onnik Kutahlian, Garabed S.Partzigian, merchants, Haig Marka-rian, Yervant Savoyan, salesmen, Levon Der Assadourain, executive, Garabed Mouradian, Rug Repairer, all eight of Montreal, Serko Boyadjian, jeweller, Bedroa Kaprielain, Carpet layer, both of Outrcmont, Mitchell Chadrjian, executive, of the town of Baie d'Urfée, Agop Pasdermakian, merchant, of Westmount, and Yervant Pasdermajian, merchant, of ^thc town of Mount Royal, for the following purposes: To constitute the Applicants and the persons who may hereafter become members of the corporation an ecclesiastical corporation having the authority and power to exercise all the rights belonging to ecclesiastical corporations with |x>rpctual succession and the right to sue and to be sued before the courts in the Province of Quebec, and elsewhere, under the name of \"The First Armenian Holy Apostolic Church\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $250.000.The head office of the corporation will l>e at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of February, 1959.P.FRENETTE, 50241-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.10872-59) Vallée Automobile Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept février 1959.constituant en corporation: Henri Vallée, garagiste.Jean Langevin, comptable agréé, et Henriette Poulin, secrétaire, tous de Ville St-Georges.Beauce, pour les objets suivants: Commerce d'automobiles et faire affaires comme garagistes, sous le nom de \"Vallée Automobile Inc.\", avec un capital total de $80.000, divisé en 400 actions communes de $100 chacune et en 400 actions privilégiées de $100 chacune.I/C siège social de la compagnie sera à Ville Saint-Géorges, district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant.5024l-o P.FRENETTE.(A.G.10872-59) Vallée Automobile Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February, 1959, incorporating: Henri Vallée, garage-keeper, Jean Langevin, chartered accountant, and Henriette Poulin, secretary, all of the Town of St.Georges, Beauce, for the following purposes: Deal in automobiles and carry on business as garage-keepers, under the name of \"Vallée Automobile Inc.\", with a total capital of $80.-000.divided into 400 common shares of $100 each and 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Town of Saint-Georges, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, tins seventeenth dav of February.1959.P.FRENETTE.50241 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14509-58) Wrightvillc Appliances Ltd.Les Appareils Wrightvillc Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre février 1959, constituant en corporation: Emile Gaumond, électricien.Joseph (A.G.14509-58) Wrightvillc Appliances Ltd.Les Appareils Wrightvillc Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of February, 1959, incorporating: Emile Gaumond, electrician.Joseph Andrew QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 11th, 19Ô9, VoJ.91, No.15 1009 Andrew Belland, commis, et Roland St-Onge, avocat, tous de Hull, pour les objets suivants: Commerce d'articles de bureau, d'appareils) ou systèmes de chauffage, accessoires électriques et instruments de musique, sous le nom de \"Wrightvillc Appliances Ltd.\u2014 Les Appareils Wrightvillc Ltée\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Hull, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre février 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241-o P.FRENETTE.Belland, clerk, and Roland St-Onge, advocate, all of Hull, for the following purposes: To carry on a business dealing with office supplies, heating systems or apparatus, electrical accessories and musical instruments, under the name of \"Wrightvillc Appliances Ltd.\u2014 Les Appareils Wright ville Ltée\", with a total capital stock of $.\")0,00(), divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will he at Hull, judicial district of Hull.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of February, 1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.Action en séparation de biens Action for separation as to property Canada, Province de Québec, district «le Canada, Province «>f Quebec, district of Mé-Mégantic, ('our Supérieure.N° 1095-1097.Co- gantic, Superior Court, No.1095-1097.Corinne Bélisle, demanderesse, vs Philippe Portier, rinne Bélisle, plaintiff, vs Philippe Fortier, défendeur.«lefemlant.Demande de séparation de biens Dame Corinne Bélisle, épouse «le Philippe Fortier, journalier, «le la ville «le Black Lake, a formé contre ce dernier une demande en séparation «le biens.Thetford Mines, le 6 avril 1959.Les Procureurs «le la demanderesse.50268-o ROBERGE & GOBEIL.Application fou separation as to property Dame Corinne Bélisle, wife of Philippe Portier, laborer, of the town of Black Lake, has instituted an action in separation as to property against her husband.Thetford Mines, April 6, 1959.ROBERGE & GOBEIL, 5()2f)S Attorneys for the plaintiff.Arrêtés en Conseil Orders in Council ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Numéro 2S9 .Section \"A\" Québec, le 2 avril 1059.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Present: The Number 2S9 Part \".1\" Québec.April 2, 1959.Lieutenant-Governor in Council.Concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments f the decree relating à l'industrie «le la construction dans la région to the construction industry in the region of de Saint-Hyacinthe.St.Hyacinthe.Attendu que.conformément aux dispositions de la Loi «le la convention collective (Statuts refondus «le Québec, 1911, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective «le travail rendue obligatoire par le décret numéro 909 «lu 25 août 1955 et amendements, relatif à l'industrie «le la construction dans la région de St-Hyacinthe, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet «le .soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil, certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition «lu 28 février 1959; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition «le l'honorable Ministre «lu Travail: Que ledit décret, numéro 909, soit modifié comme suit: 1° Les paragraphes \"a-1\" et \"c-1\" suivants sont ajoutés à Particle I: Whereas, pursuant to the provisions «>f the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941.chapter 103 and amendments), the contracting parties t«> the collective labour agreement rendered obligatory by the decree number 909 of August 25.1955 and amendments, relating to the construction industry in the region of St.Hyacinthe, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the said decree; Whereas the said petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of February 28, 1959.whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said decree, number 909, be amended as follows: 1.The following paragraphs \"a-1\" and \"c-1\" are added to article I: 1(510 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 avril 1959, Tome 91, N° lf» \"(i-l) Le mot \"artisan\" désigne toute personne \"o-l) The word \"artisan\" means any person qui exécute pour fins commerciales, de ses pro- who executes, for commercial purposes, with his près mains, un travail faisant l'objet du décret, own hands, work regulated by the decree by à forfait, à l'heure, par convention verbale, the job, by the hour, through vrebal or written écrite ou autrement.\" agreement or otherwise.\" \"c-1) Le terme \"chef d'équipe\" désigne tout \"c-1) The words \"charged hand\" mean an salarié qui a la surveillance on la direction d'au employee in charge of at least three (3) employees moins trois (3) salariés couverts par le présent covered by the present decree, for the duration décret, pour la durée de ces fonctions sur un of his functions in that capacity on a given chantier défini.\" job.\" 2° Le paragraphe \"/' de l'article I est rem- 2.Paragraph \"j\" of article I is replaced placé par le suivant : by the following: *'J) Le mot \"manoeuvre\" désigne tout salarié \"j) The word \"labourer\" means a worker préposé à la préparation manuelle du mortier, doing the manual preparation of mortar, eclanite célanite ou de toute substance similaire servant or any other similar material used in the eonstruc-à la construction et les porteurs d'oiseau.tion industry and hod carriers.\" 3° La description de la zone I apparaissant à 3.The description of zone I appearing in d'article IV est remplacée par la suivante: article IV is replaced by the following: \"Zone I: La cité de St-Hyacinthe, les munici- \"Zone I: The city of St.Hyacinthe, the muni-pàlités de la Providence, de St-Joseph, de Notre- eipalitics of La Province.St.Joseph, Notre-Dame-de-St-Hyacinthe, de St-Hyacinthe-le-Con- Dame-de-St-Hyacinthe, St-Hyacinthe-Ie-Confes-fesseur, de Douville, dc St-IIilaire, de .Mont- seur, Douville, St-IIilaire, Mont-St-IIilaire and St-IIilaire et dc Pare Otterbum.Park Otterburn.Les villes de Marieville et d'Acton Vale font The towns of Marieville and Acton Vale are également partie de la zone I; toutefois, les taux also included in zone I, but he minimum wage de salaires minima y sont de cinq cents ($0.05) rates shall be five cents ($0.05) lower than those de moins (pie ceux déterminés pour ladite zone established for the said zone in the wage scale dans la cédule apparaissant à l'article V.\" (article V).\" 4° Les paragraphes \"«\".\"6\" et \"c\" de l'article 4.Subsections \"a\", \"6\" and \"c\" of section V V sont remplacés par les suivants: t arc replaced by the following: \"a) Les taux dc salaires minima suivants «loi- \"a) The following rates of wages shall be paid vent être payés à partir de l'entrée en vigueur du from the date of the coming into force of the présent décret d'amendement: present amendment decree: Solaires horaires Hourly rates Zones 1 II Métiers \u2014 Trades : 1959 1900 1959 1960 Briqueteur, plâtrier et maçon\u2014 Bricklayer, plasterer and mason.$1.90 $2.00 $1.70 $1.80 Blanchisseur à la chaux - - Whitewashed.1.40 1.50 1.25 1.35 Calf at et jointoyeurCaulker and joint pointer.1.70 1.80 1.50 1.60 Charpentier-menuisiei\u2014Carpenter-joiner.1.70 1.80 1.50 1.60 Chauffeur de camion et de tracteui\u2014 Truck and tractor driver.1.25 1.35 1.15 1.30 Chauffeur sur les lieux du chantier\u2014Boiler fireman (on the job).1.40 1.50 1.30 1.40 Couvreur \u2014 Roofer.1.45 1.55 1.30 1.40 ( 'reuseur de caissons \u2014 ( 'aisson digger.1.85 1.95 1.85 1.95 Démolisseur (toute catégorie) \u2014 Demolisher (all categories).1 .-10 1 .50 1.25 1.35 Électricien \u2014 Electrician : Entrepreneur (services personnels) \u2014 Contractor (personal services) 2.60 2.60 2.-10 2.40 Compagnon\u2014¦ Journeyman.1.70 1.80 1.55 1.65 Êpandcur d'asphalte (Voirie) \u2014 Asphalt spreader (Roads).1.70 ISO 160 1.70 Ferblantier-couvreui\u2014Tinsmith-roofer.1.70 1.80 1.45 1.55 Finisseur de ciment \u2014 Cement finisher.1.70 1.80 1.50 l.(>0 Finisseur de plancher en mastic \u2014 Mastic floor finisher.1.70 1.80 1.70 1.80 Foreur \u2014 Drill operator.¦.1.55 1.65 1.40 1.50 Forgeron \u2014 Blacksmith.1.00 1.70 1.45 1.55 Gardien \u2014 Watchman.0.90 0 90 0.85 0.85 Journalier \u2014 Common worker.1.25 1.35 I 10 1.30 Lcttrcur pour fins commerciales - - Commercial Ictterer.1.70 1.80 1.00 1.70 Limeur de scie sur chantier\u2014Saw filer (on the job).1.70 1.80 1.50 1.60 Manoeuvre\u2014Labourer.1.45 1.55 1.35 1.45 Mécanicien en tuyauterie, plombier et poseur d'appareils de chauffage - Pipe mechanic, plumber and steamfitter : Entrepreneur (services personnels) \u2014 Contractor (personal services) 2.80 2.80 2.60 2.60 Compagnon \u2014 Journeyman.1.70 1.80 1.55 1.05 Compagnon senior en plomberie et junior en chauffage OU vice-versa Journeyman, senior rating in plumbing and junior rating in steamfitting or vice versa.1.05 1.75 1.55 1.65 Compagnon junior \u2014 Junior journeyman.1.50 1.60 1.40 1.50 Mécanicien (millwright) \u2014 Millwright.1.55 1.65 1.40 1.50 Mécanicien de machine fixe ou portative sur les lieux du chantier \u2014 Engi- neman, stationary or portable, on the job.1.50 1.60 1.35 1.45 Monteur de lignes (travail aérien) \u2014 Lineman (overhead work).1.55 1.65 1.45 1.55 Monteur de lignes (travail terrestre) \u2014 Lineman (ground work).1.45 1.55 1.35 1.45 Monteur, soudeur, brûleur et gréeur de fer structural \u2014 Structural steel erector, welder, burner and rigger.2.30 2.30 2.30 2.30 Peintre (compagnon) - Journeyman painter.1.60 1.70 1.50 1.60 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 11th, 1959, Vol.91, No.15 1611 Salaires horaires Hourly rales Zones I II Metiers \u2014 Trades: 1959 I960 1959 19(50 Poseur dc marbre \u2014 Marble layer.$1.90 $2.00 $1.70 $1.80 Poseur «le terra/./.o \u2014¦ 'IVrrazzo' layer.1.90 2.00 1.70 1.80 Poseur «le tuiles \u2014 Tile layer.1.90 2.00 1.70 1.80 Poseur «le linoléum, «le caoutchouc, «le tuiles.\u2014 Linoléum, rubber.tile, etc.layer.1.70 1.80 1.60 1.70 Poseur de lattes (bois ou métal) \u2014 Lather (wood and metal).1.70 1.80 1.50 1.60 Poseur d'armature de fer (spécialisé) \u2014 Reinforcing steel erector (specialized).,.1.70 1.80 1.70 1.80 Poseur d'appareils «le chauffage à air chaud \u2014 Hot air heating system mechanic.1.70 1.80 1.00 1.70 Poseur «le gicleurs \u2014 Sprinkler filter.1.90 2.00 1.90 2.00 Préposé aux compresseurs \u2014 Compressor operator.1.55 1.65 1.40 1.50 Préposé aux grues \u2014 Crane operator.1.65 1.75 1.45 1.55 Préposé aux monte-charge \u2014 Freight Elevator operator.J.1.50 1.60 1 .20 1.30 Pré-posé aux malaxeurs «le ciment et mortier \u2014 Cement ami mortar mixer operator.1.30 1.40 1.20 1.30 Préposé aux pelles à vapeur, à gazolinc, à l'électricité et aux niveleuses \u2014 Steam, gasoline, electric shovel ami grader operator.1.70 1.80 1.50 1.60 Pré-posé aux bouilloires (asphalte à «¦ouverture) \u2014 Kcttleinen (roofing asphalt).1.45 1.55 1.35 1.45 Préposé aux rouleux compresseurs (5 tonnes et plus) \u2014 Roller operator (5 tons or more).1.70 1.80 1.60 1.70 Préposé aux rouleaux compresseurs (jusqu'à 5 tonnes) (Voirie) \u2014 Roller operator (up to 5 tons) \u2014 roads.1.60 1.70 1.50 1.60 Rateleur «l'asphalte (voirie)\u2014Asphalt rakei-roads.1.45 1.55 1.35 1.45 Sablcur.cireur et polisseur «le plancher \u2014 Floor sander, waxer ami polisher.1.60 1.70 1 45 1.55 Tailleur «le pierre naturelle ou artificielle sur le chantier \u2014 Natural or artificial stone cutter (on the job).1.90 2.00 1 .65 1.75 Aide-tailleur dc pierre \u2014 Stone cutters' helper.1.45 1.55 1.35 1.45 Travailleur en fer ornemental \u2014 Ornamental iron worker.1.65 1.75 1.55 1.65 Aide-travailleur en fer ornemental \u2014 Ornemental iron worker's helper.1.45 1.55 1.35 1.45 Vitrier\u2014(Hazier.1.60 1.70 1.50 1.60 b) Salaires minima des apprentis-: Lis taux «le b) Minimum irages of apprentices: The follow-salaires minima suivants doivent être payés aux ing rates of wages shall be paid to apprentices, apprentis: Métiers requérant quatre (4) années d'apprentissage \u2014 For trades requi-ring a four-vear apprenticeship: 1ère année \u2014 1st vear.$0.95 $1.00 $0.85 $0.90 2cme année \u2014 2nd year.1.00 1.05 0.90 0.95 3ème année \u2014 3rd year.*.1.15 1.25 1.00 1.10 4èmc année \u2014 4th year.^.1.30 1.40 1.20 1.30 Métiers retpiérant «leux (2) années «l'apprentissage \u2014 For trades requiring a two-year apprenticeship: 1ère année\u20141st vear.1.00 1.05 0.90 0.95 2èmc année \u2014 2nd year.1.25 1.35 1.15 1.25 Métiers du fer structural: Les taux «le salaires «les Structural steel apprentice: The rates of wages apprentis doivent être basés sur les pourcen- paid to apprentices shall comply with the follow- tages suivants «les taux, minima payables aux ing percentage of the legal minimum wages paid travailleurs qualifiés en fer structural: to «pialifietl structural steel workers.1ère année.70% 1st year.70% 2ème année.85%\" 2nd year.85%\" «\u2022) Salaires minima des chefs d'équipe: Le chef c) Minimum rates of charge hands: ('barge d'équipe doit recevoir $0.10 l'heure de plus «pic hands shall receive $0.10 more per hour than the le salaire établi pour son métier seulement pour rate established for his trade only for the duration la durée de sa fonction.\" of his functions in that capacity.5° Le paragraphe \"6\" de l'article VII est 5.Paragraph \"//' of article VII is replaced remplacé par le suivant: by the following: \"b) Le travail exécuté les dimanches, le \"b) Work done on Sundays, New Year's Day, Premier jour «le l'An, la St-.Ican-Raptiste.la St.John the Baptist Day, Labour Day and Fête du Travail et le Jour de Noël doit être Christmas Day shall be paid at the rate of rémunéré au taux de salaire double, par rapport double time based on the wage rate actually paid, au taux «le salaire effectivement payé.Toutefois, l'Epiphanie, l'Ascension, La Tous- However, on Epiphany Day, Ascension Day, saint et ITmniaculéc-Conccption, afin de permet- Ail Saints Day and Immaculate Conception Day tre aux travailleurs «l'accomplir leurs devoirs the starting hour shall be 9.00 a.m.or later in religieux, la journée «le travail ne débutera pas order to make it possible for workers to accom-avant 9.00 a.m.Aucune travailleur ne pourra plish their religious duties.No worker may be être puni pour ne pas s'être rendu au travail punished for having been absent on such «lays 1612 GAZETTE OFF 1CIELLE DE QUÉBEC, Quebec, 11 avril 1959, Tome 91, N° 15 pendant ces jours à condition d'avoir averti son providing lie notified the employer the day employeur la veille.\" before.' 6° ix' paragraphe \"c\" «le l'article VIII esl 6.Paragraphe \"c\" of article VIII is replaced remplacé par le suivant: by the following: \"e) Prise de congé: A moins qu'il ne s'agisse \"c) Period during which vacation is to be given: de travaux urgents en plomberie ou électricité, Except for urgent electrical or plumbing services, l'employeur doit donner à son salarié y ayant employers must give the vacation to which droit, le congé prévu par le présent article, dans an employee is entitled according to the present la première semaine complète «lu mois d'août de section the first complete week of the mouth of chaque année.\" August, «each year.\" 7° Les alinéas 3° et 4° «lu pragraphe \"/\" de 7.Sub-paragraphs 3 and 1 «>f paragraph \"/\" of l'article VIII sont remplacés par les suivants: article VIII are replaced by the following: \"3° conserver jusqu'à prise «le congé ou, s'il \"3.keep each employee's vacation-with-pay y a résiliation antérieure du contrat de travail, stamp book until the vacation period or during durant le temps d'emploi, les livrets de congés de the time of employment should the employee's chacun de ses salariés.labour contract be previously cancelled; 4° remettre à chacun de ses salariés à la prise 4.give back his vacation-with-pay stamp book dc congé ou lors de la résiliation antérieure de to each one of his employees at the time of son contrat de travail, son livret «le congés.vacation or at the time of the previous cancel- lation of his labour contract.L'employeur qui fournit à un salarié un livret The employer who provides his employee «le congés payés peut en déduire le coût du salaire with a vacation-with-pay stamp book may deduct dc ce dernier.\" from the employee's wages the cost .of such book.\" 8° L'alinéa 2° du paragraphe \"g\" «le l'article 8.Sub-paragraph 2 of paragraph \"g\" of article VILE est remplacé par le suivant: VIII is replaced by the following: \"2° réclamer i des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le premier avril 1959.Ix* Sous-secrétaire de la province.50251 JEAN BRUCHÉSI.Distribution d'actif Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu d'un règlement adopté par le Bureau de Direction de \"Syndicatd'Expansion Industrielle de Plcssis-villc Inc.\".le six mars mil neuf cent cinquante-nenf, cette compagnie distribuera son actif à ses actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.Plcssisville, le 27 mars 1959.Le Notaire de Syndicat «l'Expansion Industrielle dc Plcssisville Inc., 50254-O C.BENOIT Cil ARTIER.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Union Coopérative dc Malarlie\", en date du 24 janvier 1959.dont le siège social est situé à Malartic, comté d'Abitibi-Est, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le dix-huit mars 1959.Ix* Sous-secrétaire «le la province, 50255-o JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration «le fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire Marie Reine «les Coeurs de Mont irai\", en date du 4 mars 1959, dont !«\u2022 siège social est situé à Montréal, district judiciaire «le Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat «le la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le trois avril 1959.Le Sous-secrétaire de la province, 50259-o JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Garage Coopératif Beauceville\", en date du 12 mars 1959, «lont le siège social est situé à Beauceville, comté de Beauce, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le trente et un mars 1959.IiC Sous-secrétaire de la province, 502G6-O JEAN BRUCHÉSI.(A.G.12188-54) Notice is given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved, oq March thirty-first, 1959, general by-law No.1 of \"La Corporation des Administrateurs Professionnels - The Corporation «>f Professional Administrators\", pursuant l the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, the first day of April.19.59.JEAN BRUCHÉSI, 50251 Uiuler Secretary of the Province.Distribution op assets i Notice is hereby given that in accordance with a By-law adopted by the Board f \"The Priory School Inc.\", as adopted at a special general meeting held on January 19th, 1959, have been approved on March 24th, 1959, by the Honourable the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of March, 1959.JEAN BRUCHÉSI, 5028l-o Ululer Secretary «>f the Province. 1616 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec 11 avril 1969.Tome 91, N° 16 Chartes \u2014 Abandon de avis d'abandon de charte La Compagnie \"Syndicat d'Expansion Industrielle de Plessisville Inc.\", incorporée suivant la premiere partie de la loi des compagnies de Québec et ayant son siège social à IMessisville, dans le district «l'Arthahaska.donne, par les présentes, avis qu'elle s'adressera au Procureur Généra] «le la Province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la loi «les compagnies de Québec.Plcssisville.le 27 mars 1959.Le Notaire «le Syndicat d'Expansion Industrielle «le Plessisville Inc.50264-o c.BENOIT CHARTIER.Palomer Knitting Mills Ltd.Avis d'application pour permission d'abandonner une charte Avis est donné «pie \"Palomer Kintting Mills Ltd.\", «pii a son bureau principal dans la cité de Montréal, demandera la permission d'abandonner sa charte en vertu de la Loi des Compagnies dc Québec.Montréal, le 30 janvier, 1959.Palomer Knittinc.Mills Ltd., Par: Ix?Secrétaire.NATHAN LACKSTEIN.Les Procureurs du requérant.Orcnstcin & Ruby 637 ouest.rue Craig, Montréal, Québec.50258-.Charters \u2014 Surrender of Notice os surrender of charter The Company \"Syndicat d'Expansion Imlus-trielle de Plessisville Inc.\", incorportaed under Part.I of the (Juchée Companies' Act ami having its head at Plessisville, in the district of Artha-haska, hereby gives notice that it will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter pursuant to the provisions of the Quebec Companies' Act.Plessisville.March 27.1959.C.BENOIT CHARTIER, Notary for Syndicat d'Expansion Industrielle 50254 «le Plessisville Inc.Palomer Knitting Mills Ltd.Notice of petition for leave to surrender its charter Notice is hereby given that \"Palomer Knitting Mills Ltd.\", having its head ollicc in the city of Montreal, will apply for leave to surrender its charter in accordance with the Quebec Companies' Act.Montreal, January 30th, 1959.Palomer Knitting Mills Ltd., Per: NATHAN LACKSTEIN.Secretary.Orcnstein & Ruby, 1 637 Craig Street West, Montreal, Quebec, Attorneys for Petitioner.50258-o Compagnies dissoutes (P.G.11168-55) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte dc la compagnie \"A.Fcldman Company\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 4 mars 1939.Avis est de plus donné qu'à compter du trente et un mars 1958, la«lite compagnie a été dissoute.Daté «lu bureau du Procureur général, le premier avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241-o P.FRENETTE.(P.G.13009-58) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Dorval Properties Ltd.\", constituée en corporation en vertu «le ladite première partie dc la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date «lu 7 novembre 1953.Avis est «le plus donné qu'à compter du trente et un mars 1959.ladite compagnie a été dissoute.Companies Dissolved (A.G.11168-55) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 276, R.S.Q., 1941, ami subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"A.Fcldman Company\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act.by letters patent dated March 4.1939.Notice is also given that from and after March thirty-first 1958, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of April, 1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13009-58) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 270, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Dorval Properties Ltd.\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated November 7, 1953.Notice is also given that from and after March thirty-first, 1959, the sai«l company has been dissolved. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April llih, 1959, Vol.91.No.15 1617 Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 5024l-o P.FRENETTE.(P.G.12959-58) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Drummond Café Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies dc Québec, par lettres patentes en date du 6 août 1942.Avis est dc plus donné qu'à compter du trente et un mars 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 5024l-o P.FRENETTE.(P.G.12095-58) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 dc ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \".Hamilton Nursing Home Inc.\", constituée cii corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Que-tac, par lettres patentes en date du 3 mai 1952.Avis est de plus donné qu'à compter du trente et un mars 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 5024l-o P.FRENETTE.(P.G.11853-58) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 27(i, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Hamelin & Hubbard Industries Corporation\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 2 février 1957.Avis est de plus donné qu'à compter du trente mars 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1959.' L'Assistant-procureur général suppléant, 50241-o P.FRENETTE.(P.G.14211-58) Avis est .donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"J.W.Martincau Ltée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, pat-lettres patentes en date du 9 novembre 1954.Avis est de plus donné qu'à compter du trente mars 1959, ladite compagnie a été dissoute.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of April.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12959-58) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has bee pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Drummond Café Inc.\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act.by letters patent dated August 0.1912.Notice is also given that from and after March thirty-first, 1959, the said company has been dissolved.Dated at the oflice of the Attorney General, this first dav of April.1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12095-58) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 276, R.S.Q.1911.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Hamilton Nursing Home Inc.\", incorporated under said, Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated May 3, 1952.Notice is also given that from and after March thirty-first, 1959.the said company has been dissolved.Dated at the oflice of the Attorney General, this first dav of April.1959.P.FRENETTE, 50211 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11853-58) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender'of the charter of the company \"Hamelin & Hubbard Industries Corporation\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated February 2.1957.Notice is also given that from and after March 30.1959.the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of April.1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14211-58) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.section 26.chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"J.W\".Martincau Ltée\".incorporated Under said Part I of the Quebec Companies' Act.by letters patent dated November 9.1954.Notice is also given that from and after March 30.1959, the said company has been dissolved. 1618 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec II avril t969, Tome 91, S° tô Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 50241-O P.FRENETTE.(P.G.10442-59) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec.Statuts refondus de Québec.1911.chapitre 27b.article 2(5, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi.il a plu au Procureur général «l'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Kent Avenue Investment Corp.\".constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 10 mai 195Ô.Avis est i des compagnies «le Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi, il a plu au Procureur général «l'accepter* l'abandon de la charte «le la compagnie \"Montreal Industrial Land Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 4 novembre 1912.Dated at the office of the Attorney General, this first day of April, 1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10442-59) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.section 20, chapter 276, R.S.Q.1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Kent Avenue Divestment Corp.\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated May 16, 1955.Notice is also given that from and after March thirty-first 1959.the said company has been dissolved.Dated at the office «>f the Attorney General, this first day of April.1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14337-58) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 270.R.S.Q., 1941.and subject t the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Les Immeubles C.D.Jean Ltée\", incorporated under said Part I «»f the Quebec Companies' Act, by letters patent dated May 22.1957.Notice is also given that from and after March thirtieth 1959.the said company has been dissolved.Dated at the oflice «>f the Attorney General, this first day «>f April.1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12545-58) Notice is hereby given that under Part I of the Quebei des compagnies de Québec.Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 dc ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"St.Philomènc Sand & Gravel (Thibert Pit) Ltd.\", constituée en corporation en vertu de-ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 18 décembre 1950.Avis est dc plus donné qu'à compter du trente et un mars 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241-o P.FRENETTE.(P.G.11862-58) Avis est donné qu'en vertu' de la première partie dc la Loi des compagnies de Québec.Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi.il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Swanson Mines Ltd.\" (No Personal Liability), constituée en corporation en vertu de là Loi des compagnies minières de Québec, par lettres patentes en date du 13 avril 1955.Avis est de plus donné qu'à compter du trente mars 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 5024l-o P.FRENETTE.(P.G.13996-58) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Veritas Inc.\", constituée en corpo- (A.G.13884-58) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q.1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of I he charter of the company \"Robert Limitée\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated August 23.1910.Notice is also given that from and after March thirty-first 19.59.^ the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of April, 1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10245-59) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 276, R.S.Q.1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"St.Philomènc Sand & Gravel (Thibert Pit) Ltd.\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated December 18, 1956.Notice is also given that from and after March thirty-first.1959, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of April.1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11862-58) Notice is hereby given tluil under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 270, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased lo accept the surrender of the charter of the company \"Swan-son Mines Ltd.\" (No Personal Liability), incorporated under the Quebec Mining Companies' Act.by letters patent dated April 13, 1955.Notice is also given that from and after March thirtieth 1959, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of April.1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13990-5S) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Veritas lac\", incorporated under Part I of the Quebec r 1020 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 avril 1959, Tome 91, N° 16 \"ration en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 3 octobre 1950.Avis est de plus donné qu'à compter du trente et un mars 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 50241-O P.FRENETTE.Curatelle publique Canada \u2014 Province de Québec District de Hull Succession vacante de Henry Allen, en son vivant de Canton de Buckingham.Le soussigné donne avis que cette succession a été déclarée vacante en vertu d'un jugement rendu le 11 mars 1957 par un juge de la cour supérieure siégeant à Hull dans le district do Hull (pie.sous l'autorité de la loi de la curatelle publique (9 Geo.VI, c.02).il est curateur d'oflice à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.LE CURATEUR PUBLIC.187, rue Sainte-Catherine (Ouest), 50270-O Montréal 18.Département do l'Instruction Publique N° 56-59.Demande est faite dc détacher de la municipalité scolaire de St-Alpbonse-de-Thetford, dans le comté dc Mégantic, les lots suivants du cadastre officiel du canton d'Irlande ainsi que toutes leurs subdivisions présentes et futures, savoir: 541 à 555 inclusivement du rang IX et 562 à 576 aussi inclusivement du rang X, pour les annexer pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire de la cité de Thetford-Mines, même comté.Québec, le 26 mars 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 50205-14-2-O O.J.DÉSAULNIERS.N° 269-59.Demande est faite d'ériger en nouvelle municipalité scolaire, sous le nom de Louiseville, comté de Maskinongé, le territoire actuel des deux municipalités scolaires de la paroisse de Hivière-du-Ixmp, dans le comté de Maskinongé.et de Ironise-ville, même comté*.Québec, le 2 avril 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 50235-1 l-2-o O.1.DÉSAULNIERS.N° 432-58.Demande est faite d'annexer le territoire actuel dc la municipalité scolaire de la paroisse de Nico-let, dans le comté de Nicolet, à celle de la ville dc Nicolet, même comté.Québec, le 2 avril 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 50236-14-2-O O.1.DESAULNIERS.Companies' Act, by letters patent dated October 3, 1950.Notice is also given that from and after March thirty-first, 1959, the said company has been dissolved.Dated at the oflice of the Attorney General, this first day of April, 1959.P.FRENETTE, 50241 Acting Deputy Attorney General.Public Curatorship Canada Province of Quebec District of Hull Vacant estate of Henry Allen in his lifetime of the township of Buckingham.The undersigned gives notice that the said estate has been declared vacant in virtue of a judgment rendered on March 11, 1957, .by a judge of the Superior Court sitting at Hull, in the district of Hull, that he is, under the authority of the Public Curatorship Act (9 Geo.VI ch.62), curator cx-officio to the said estate, ami that he will receive, at the address given below, the payment of all debts owing to the said estate ami proof of all claims against it.THE PUBLIC CURATOR, 187, Sainte-Catherine Street (West), 50270 Montreal 18.Department of Education No.56-59.Application is made to detach from the school municipality of St-Alphonsc-dc-Thctford, in the county of Mégantic, the following lots in the official cadaster of the township of Irlande as well as all their present and future subdivisions, to wit: 541 to 555 inclusive of range IX and 562 to 570 also inclusive of range X, to annex them for the Catholic ratepayers only, to the school municipality of the city of The! ford-Mines, same county.Quebec, March 26, 1959.0.1.DÉSAULNIERS, 50205-14-2 Superintendent of Education.No.269-59.Application is made to erect into a new school municipality, under the name of Louiseville, county of Maskinongé, the present territory of the two school municipalities of the parish of Rivière-du-1/Oup, in the county of Maskinongé, and of l/ouiseville, same count v.Quebec, April 2.1959.0.J.DÉSAULNIERS, 50235-14-2 Superintendent of Education.No.432-58.Application is made to annex the present territory of the school municipality of the parish of Nicolet in the county of Nicolet.to that of the town of Nicolet, same count v.Quebec, April 2, 1959.0.J.DÉSAULNIERS, 50236-14-2 Superintendent of Education. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 11th, 1959, Vol.91, No.15 1621 N° 500-57.Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de la paroisse de Macamie, dans le comté d'Ahitihi-Oucst, à celle de Macamie, même comté.Québec, le 3 avril 1059.Le Surintendant de l'Instruction publique, 50207-15-2-o O.J.DÉSAULNIERS.i Département des Mines AVIS Avis est donné qu'en vertu de l'article 49 dc la loi des Mines «le Québec (Statuts refondus «le Québec, 1941, chapitre 190), et pour défaut d'accomplissement «les comlitions déterminées par cette disposition de la loi, les concessions minières couvrant les parcelles dc terrain ci-après mentionnées, seront révoquées en tout temps après le quinzième jour d'avril 1959.Liste «les concessions: 1° Bloc 30 du canton «le Beauchastel, «listrict électoral de Rouyn-Noranda, (183 acres), concédée à .1.A.Viger le 8 octobre 1920 et subsé-quemincnt transportée à Wasamac Mines Limited.2° Blocs 07, 08, 09 et 70 du canton de Rouyn, «listrict électoral de Rouyn-Noranda, (158 acres), concédée à P.E.Goyettc le 25 octobre 1920 et subséquemment transportée à A.E.Goyette.Québec, le 16 mars 1959.Le Sous-ministre «les Mines, 50233-14-2-0 A.O.DUFRESNE.No.500-57.Application is made to annex the present territory of the school municipality of the parish of Macamie, in the county of Abitibi-West, to that of Macamic, same county.Quebec, April 3, 1959.O.1.DÉSAULNIERS, 50207-15-2 Superintendent of Education.Department of Mines NOTICE Notice is hereby given that under section 49 of the Quebec Mining Act (R.S.Q.1941, chapter 190), and in default of the performance of the conditions determined by the provision of the law, the mining concessions covering the blocks of land hereinafter described, will be cancelled at any time after the fifteenth of April, 1959.List of concessions: 1.Block 30, township of Beauchastel, electoral district of Rouyn-Noranda, (183 acres), conceded to J.A.Viger on the 8th of October, 1926, and subsequently transferred to Wasamae Mines Limited.2.Blocks 67, 08, 09 and 70.township of Rouyn, electoral district of Rouyn-Norandà, (158 acres), conceded to P.E.Goyette on the 25th of October, 1920, ami subsequently transferred to A.E.Goyette.Quebec, March 16th, 1959.A.0.DUFRESNE, 50233-14-2-o Deputy Minister of Mines.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, ministre «lu Travail, «hume avis, par les présentes, conformément aux dispositions «le la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 103 et amendements), que les parties contract aides à la convention collective «le travail relative aux métiers «le barbier, coiffeur et coiffeuse dans le «listrict de Saint-François, rendue obligatoire par le décret numéro 255 «lu 5 mars 1953 et amendements, lui ont présenté une requête à l'effet «le soumettre à l'appréciation et à la décision «lu Lieutenant-gouverneur en conseil des modifications audit décret savoir: 1° La désignation «les parties contractantes de première part sera remplacée par la suivante: \"D'une part: L'Association «les Maîtres cl Artisans-Barbiers «lu «listrict de St-Francois; L'Association patronale «le la Coiffure «lu district de St-Francois:\" 2° La première phrase du paragraphe \"a\" «le l'article XII sera remplacée par la suivante: \"a) Aucun apprenti n'est accepté avant d'avoir seize (16) ans révolus ou après trente-cinq (35) ans.\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel cidre en vigueur à la date de Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that contracting parties to the Collective Labour Agreement relating to the barbering and hair-drcssing trades in the district of St.Francis, rendered obligatory by the decree No.255 of March 5th, 1953.and amendments, have peti-tioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council certain amendments, to the said decree, to wit: 1.The designation of the contracting parlies of the first part will be replaced by the following: \"On, Till\".one part: L'Association des Maîtres et Artisans-Barbiers «lu «listrict «le St-Françpis; L'Association patronale «le la Coiffure du district «le St-Francois;\" 2.The first sentence of paragraph \"o\" of article XII will be replaced by the following: \"a) No apprentice is accepted before sixteen (16) or after thirty-five (35) years of age.\" The publication of the present notice docs not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order in Council which conies into force on the 1622 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec.11 avril 19Ô9, Tome 91.N° 16 sa publication «laits la Gazette officielle de Québec.Dînant les trente jours à compter «le la «late «le publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.\\a- Sous-ministre «lu Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère «lu Travail.Québec, le 11 avril 1959.50273-O AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette.Ministre «lu Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions «le la Loi «le la convention collective (S.R.Q.1941.chapitre 163 et amendements), que le Conseil «les Métiers «h' la Construction «le Hull et du district lui a présenté une requête à l'effet «l'être traité comme partie CO-COntractante «le deuxième part à la conventùm collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro S10 «lu 14 août 1957 et amendements, relatif à l'industrie et aux métiers dc la construction dans la région «le Hull, au lieu et place du Conseil Provincial de la Fraternité Unie des Charpentiers-Menuisiers d'Amérique.I^i publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions «pli y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut remire obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la «late de sa publication «lans la Gazette officielle dc Québec Durant les trente jours à compter «le la date de publication «le cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections «pie les intéressés pourront désirer formuler.Ia- Sous-ministre «lu Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 11 avril 1959.50273-O Département de la Voirie AVIS Le ministère «le la Voirie cessera à l'avenir «l'entretenir les sections «le routes ci-après désignées, parce qu'elles sont «levenues inutiles pour la circulation: Dans la municipalité «le la paroisse «le St-Louis-de-Chambord, comté dc Robcrval: Chemin du Lac à l'Ours: Une section de 1,295 pieds, à l'ouest «lu nouveau chemin, sur ou vis-à-vis les lots Nos 42B et 42A, rang I et 42, rang II; une section de 1,550 pieds, à l'est du nouveau chemin, sur ou vis-à-vis les lots Nos 42, 41B et 41A, rang II; une section de 800 pief this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of labour will consider the objections which the interested par-tics may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy MinisterOf Labour.Department of Labour, Quebec, April 11.1959.50273-O Department of Roads NOTICE j \u2014 The Department of Roads shall cease hereafter to maintain the sections of roads «iescribed hereinafter because they have become useless to traffic: In the municipality of the parish of St.Louis-de-Chambord, county of Roberval: Lac à l'Ours Road : A section of 1,295 feet, west of the new road, on or facing lots Nos.42B and 42A.range I and 42, range II; a section of 1,550 feet, east of the new roa«l, on or facing lots Nos.42, 41B and 41 A, range II; a section of 800 feet, east of the new road, on or facing lot No.39, range II; a section of 395 feet, west of the new road, on or facing lots Nos 43A and 42B, range I.In the county of Berliner: In the municipality of the parish of Ste.( Jeneviève-de-Berthier : Petit Bois d'Autray Road: A section of 250 feet, north of the new road, on or facing lots Nos 54 and 55. QUEBEC OFFICIAL CA'AEl TE, Quebec, April nth.1969, Vol.91, No.\\6 1623 Dans la municipalité «le la paroiss»- «!«\u2022 St-Norbert : Chemin «le ligne Ste-Elisabcth : Une section «le 5,111 pieds, depuis le chemin Côté Sud «lu Ruisseau Ronavcnture jusqu'à la limite «le la munh-ipalité.sur ou vis-à-vis les lots Nos 347 et 348.Dans le comté dc Joliettc: Dans la municipal it «'\u2022 «le la paroisse «le St-Alphonse-«le-Rodriguez: Chemin du rang II: Une section de 935 pieds, à lest «lu nouveau chemin, sur ou vis-à-vis les lots Nos 24R et 25A, rang II, 25A et 25< ' rang III.Dans la municipalité de la paroisse «le St-Ambroisc-«lc-Kili des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement dc \"North Pacific Insurance Company Limited\" sont annulés à compter du 25 mars 1959.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 25 mars 1959.Pour le Ministre des finances dc la province, GEORGES LAFRANCE, 50193-14-2-o Surintendant des assurances.Department of Finance Insurance Notice of cancellation of license and registration Whereas \"North Pacific Insurance Company Limited\", whose head office is situate in Hong Kong, China, has reinsured all its business in the Province of Quebec with \"Union Insurance Society of Canton, Limited\", whose head office is situate in Hong Kong, China, according to a reinsurance agreement entered into by these two companies on the 12th of February, 1959; Whereas \"North Pacific Insurance Company Limited\", has otherwise complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"North Pacific Insurance Company Limited\" arc cancelled as from the 25th of March, 1959.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 25th of March, 1959.For the Minister of Finance of the Province, ( 1 FORGES LA FRANCE, 50193-14-2-o Superintendent of Insurance.Office des Marchés Agricoles Quebec Agricultural Marketing du Québec Board AMENDEMENT Le Plan conjoint des Producteurs-fournisseurs de lait à la Laiterie Mont Saint-Bruno.Le plan conjoint ci-dessus, sanctionné dans la Gazelle officielle de Québec du 17 août 1957, est amendé ainsi qu'il suit: \"Les prélevés par l'acheteur, à même les montants payables aux producteurs n'excéderont pas deux cents (S0.02) le cent livres de lait.\" Montréal, 6 avril 195!).Ix- Président.(Juge) GEORGES-H.HÉON.Le Secrétaire, 50264-O LÉONARD ROY.AMENDEMENT Iaî Plan conjoint des Producteurs de bois de pulpe de Rimouski-Matapédia.Les agents tie négociation et dc vente qui étaient désignés dans la Gazette officielle dc Québec du 12 juillet 1958 ainsi qu'il suit: \"Le Syndicat Spécialisé des Producteurs dc dc Bois de Rimouski ou ses délégués\" sont, à partir d'aujourd'hui, \"L'office des Producteurs ou ses délégués.\" Montréal, 6 avril 1959.Le Président, (Juge) GEORGES-H.HÉON, Le Secrétaire, 50264-O LEONARD ROY.AMENDMENT The joint plan of the producers-suppliers to La Laiterie Mont Saint-Bruno.The above joint plan sanctioned in the Quebec Official Gazette of August 17th, 1957, is amended as follows: \"The levy by the buyer, from the sums payable to the producers shall not exceed two cents (SO.02) per hundred pounds of milk.\" Montreal, April 0th, 1959.(Judge) GEORGES-H.IIEON, Chairman.LÉONARD ROY, 50264-t) Secretary.AMENDMENT The Rimouski-Matapédia Pulpwood Producers' plan.The negotiating and selling agents, which were designated in the Quebec Official Gazette of July 12th, 1958, as follows: \"Le Syndicat Spécialisé des Producteurs de Bois de Rimouski or its delegates\" shall be, as of to-day, \"The producers' board or its delegates.\" Montreal, April 6th, 1959.(Judge) GEORGES-H.HÉON, Chairman.LÉONARD ROY, 50264-O Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April llfh, 1959, Vol.91, So.15 1625 Ordre de Cour Canada, province de Québec, district de St-Hyncintlie, Cour Supérieure, N° 10557.Joseph Quintal, de Ste-Pie de Bagot, district dc St-Ilyacinthc, demandeur, VS Emile Nichols, de St-Pie.district de St-Hyacinthe, défendeur, et I/IIonorable Johnny S.Bourque, en sa qualité de ministre des Finances de la Province de Québec, tiers-saisi, et Arthur Dupré, garagiste de Belrcil, district de Richelieu, intervenant.AVIS *U\\ CRÉANCIERS DU DÉFENDEUR Les créanciers de Emile Nichols de Saint-Pie de Ragot, «listrict de St-IIyacintlie, sont invités à «léposer leurs réclamations, avec titres à l'appui, dans la quinzaine de la première insertion des pré-seules, au Greffe de la Cour Supérieure à Saint-Hyacinthe, entre les mains du protonotaire, le tout conformément aux article 673, 074 et 004 CP.Par ordre de l'honorable juge François Caron, St-Hyacinthe, ce 1 avril 1959.Le Protonotaire.Cour Supérieure, district de Saint-Hyacinthe, 50234-14-2-0 LIONEL LEBLANC.Sièges sociaux Canada ¦\u2014 Province de Québec District de Montréal Dans l'affaire de: A.& W.Restaurants Ltd.Avis de situation du siège social Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"A.& W.Restaurants Ltd.\", constituée en corporation en vertu des dispositions de In première partie de la Loi des compagnies dc Québec, le lie jour de février 1959, et ayant son siège social en la cité de Montréal, en la province de Québec, a établi son bureau à 1500 ouest, rue Ste-Catherine, chambre 214.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 17e jour de février 1959.(Sceau) Ix- Président, 50240 MERVYN SALTZMAN.Dans l'affaire de: Beàconsfield Shopping Centre Inc.Avis de situation du siège social Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Beàconsfield Shopping Centre Inc.\", constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, le 16e jour de décembre 1953, sous le nom de \"Beàconsfield Development Corp.\" et ayant eu son nom changé par des lettres patentes supplémentaires en date «lu 10e jour d'avril 1957, et ayant son siège social situé en la cité de Montréal, eu ladite province, a «'tabli son bureau à 7101 Côte St-Luc, chambre 210, Montréal, Québec.s Rule of Court Province of Quebec, district of St.Hyacinthe Superior Court, No.10557.Joseph Quintal, of Ste-Pie de Bagot, «listrict of St-Hyacinthe, plain-thilf, vs Emile Nichols, of Ste-Pie, (listrict of St.Hyacinthe, defendant and L'Honorable Johnny S.Bounpie, in his quality of minister of Finances of the Province of Quebec, garnishee, and Arthur Dupré, garage keeper of Beloeil, district of Richelieu, intervenant.NOTICE TO THE CREDITORS OF THE DEFENDANT The creditors of Emile Nichols of Sainte-Pie -de Bagot, district of St.Hyacinthe, are invited to file their claims, together with documents, in evidence, within 15 days of the first insertion of the present notice, at the oflice of the Superior Court at Saint-Hyacinthe in the bands of the prothonotary in accordance with articles 073, 674 and 694 CP.By order of the honorable Justice, Francis Caron.Saint-IIyacinthe, April 1st, 1959.LIONEL LEBLANC, The Prothonotary of the Superior Court, 50235-14-2-o district of St.Hyacinthe.Head Offices Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal In the matter of: A.& \\Y.Restaurants Ltd.Notice of location of head office Notice is hereby given that \"A.& W.Restaurants I,t«l.\", incorporated umlcr the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act, on the 11th day of February.1959, and having its head office in the city of Montreal, in the Province of Quebec, has established its office at 1500 St.Catherine Street West, room 211.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head oflice of the company.Datctl at Montreal, this 17th day of February, 1959.(Seal) MERVYN SALTZMAN, 50240-o President.In the matter of : Beàconsfield Shopping Centre Inc.Notice of location of head office Notice is hereby given that \"Beàconsfield.Shopping Centre Inc.\", incorporated uiuler the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act, on the 10th day of December, 1953, under the name of \"Beàconsfield Development Corp.\" and its name changed by supplementary letters patent dated the 10th day of April, 1957.and having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its oflice at 7101 Côte St.Luc Road, room 210, Montreal, Quebec. 1626 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, il avril 1969, Tome 91, N° 15 A compter de la date de cet avis, ledit bureau From and after the date of this notice, the sera considéré par la compagnie comme étant said office shall be considered by the company son siège social.as being the head oflice of the company.Daté à Montréal, ce 31e jour de mars 1959.Dated at Montreal, this 31st day of March, 1959.(Sceau) Le Président, (Seal) LEO (iOLDFARB, 60247 LEO ( IOLDFARB.50247-O President.Canada Province de Québec District de Montréal I )ans l'affaire de: Doreal Investments Ltd.Avis de situation du siège social Avis est.par les présentes, donné que la compagnie \"Doreal Investments Ltd.\".constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, le le jour de décembre 105S, et ayant son siège social en la cité de Montréal, en ladite province, a établi son bureau à 105 ouest, rue St-Jacqucs.A compter de la date de cet avis ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté en la cité de Montréal, ce 12e jour de janvier 1959.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 502 IS SHIRLEY G.DIXON C.R.Canada Province of Quebec District of Montreal In the matter of : Doreal Investments Ltd.Notice of location of head oflice Notice is hereby given that \"Doreal Investments Ltd.\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act on the Ith day of December, 195S, and having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its oflice at 105 St.James Street West : From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company; Dated at the city of Montreal, this 12th day of January, 1959.(Seal) \" SHIRLEY G.DIXON, Q.C., 50248-1 » Secretarv-Treasurer.Avis est, par les présentes, donné (pie la Notice is hereby given that \"Lavallée Co.compagnie \"Lavallée Co.Ltd.\".constituée en Ltd.\", incorporated by letters patent under the corporation par lettres patentes eu vertu de la Quebec Companies'Act, on February 28th, 1958, Loi des compagnies de Québec, le 28 février 1958, has established its head oflice at 777 Chapleau a établi son siège social à 777 rue Chapleau, Street, Sherbrooke, Quebec.Sherbrooke, Québec.Daté à Sherbrooke, ce 23e jour de mars 1959.Dated al Sherbrooke, this 23rd dav of March.1959.(Sceau) Le Président.(Seal) G.A.LAVALLÉE, 50249 (L A.LAVALLÉE.50249-n President.AVIS Avis est par les présentes donné que \"Unie Equipment Inc.\", a établis son siège social à 5,780 rue Paré.Ville Mont-Royal, district de Montréal, province de Québec.Daté à Montréal.Que., ce 31 mars 1959.50250-O Le Secrétaire.MARCEL PICHÉ, C.R.Avis est donné (pie la compagnie \"Longwood Acres Inc.\".constituée en corporation par lettres patentes en date du lOèinc jour de janvier 1959.et ayant son bureau principal dans Magog, district de St-François.a établi son bureau au numéro 22, rue Laurier.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Magog.district de St-François.ce 19ème jour de janvier 1959.(Sceau) Le Président.50253-O J.ALLAN SCOTT.Avis est par les présentes donné (pie \"Industrial Materials Supply Company Ltd.\" a établi son siège social à 207 avenue Dunbar, ville Mont-Royal, district de Montréal, province de Québec.Signé à Montréal.Que., ce Oème jour de mars 1959.Le Secrétaire.50256-O MARCEL PICHE, C.R.NOTICE Notice is hereby given that \"Unie Equipment Inc.\", has established its head office at 5,780 Paré Street, Town of Mount Royal, district of Montreal, Province of Quebec.Dated at Montreal, Quebec, this 31st dav of March.1959.MARCEL PIC TIE, Q.C., 50250-O Secretary.Notice is hereby given that the \"Longwood Acres Inc.\".company incorporated by patent letters on January Kith, 1959 and having its head office in Magog, district of St.Francis, has established its office at 22 Laurier street, Magog.From and\"after the date of this notice the said oflice shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Magog, this 19th dav of Januarv, 1959.(Seal) J.ALLAN SCOTT, 50253-O President.Notice is hereby given that \"Industrial Materials Supply Company Ltd.\" has established its head office at 267 Dunbar Avenue, town of Mount Royal, district of Montreal, Province of Quebec.Signed at Montreal, Que., this 6th day of March 1959.MARCEL ITCHÉ, Q.C., 50256-O Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 11th, 1969, Vol.91, So.16 1027 Les Entreprises du Charme Inc.Avis de la situation «lu siège social Avis est, par les présentes, donné que \"Les Entreprises du Charme Inc.\", une compagnie dûment constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes émises en date du 2Sièinej our d'avril 1968, et ayant son siège social à Val David, province de Québec, y a établi son bureau à Val David.Co.Terrebonne.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la Compagnie comme son siège social.Donné à Val David, ce llièine jour de mars 1959.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 50257-o JEANNE DUCHARME.Avis de changement du bureau principal Avis est donné (pie la compagnie \"La Cie d'Immeubles du Lac St-Louis Inc.\" const il née en corporation suivant lettres patentes, en date du 22ième jour de juillet 1954, et ayant son bureau principal dans la cité de Beauharnois, où (die avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui, au N° 110, de la rue Ellicc.l'a transporté au numéro OS de la rue Ellicc, en la cité de Beauharnois.A compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie connue étant son bureau principal.Donné à Beauharnois, ce troisième joiîr d'avril, 1959.Le Président, 50262-o FRANÇOIS DORVAL.Avis est donné que \"La Ligue des Propriétaires d'AMaBaic Incorporée \u2014 AMaBaic Proprietors I/caguc Incorporated\", constituée en Corporation par lettres patente en date du 31 janvier 1959, et ayant son bureau principal à A Ma Raie, ville de Pierrefonds, comté de Jacques-Cartier, district de Montréal, a établi son bureau au N° 4771 du Roulevard Pierre-Lauzon.A compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la corporation comme étant son bureau principal.Daté à Pierrefonds.ce 2-1 mars, 1959.Le Président.50265-o JEAN GAGNON.Soumissions Les Entueprises du Charme Inc.Notice of the situation of the Head Oflice Notice is hereby given that \"Les Entreprises du Charme Inc.\".a company duly incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act.by letters patent issued under date of April 28th, 1958, and having its head oflice at Val David.Province of Quebec, has established its office at Val David.Co.Terrebonne.Prom aud after th.- date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head oflice.Given at Val David, this 11th dav of March, 1959.(Seal) JEANNE 1)1'CHARME.50257 Secretary-Treasurer.Notice of change in location of head office Notice is given that the company \"La Cie d'Immeubles du Lac St-Louis Inc.\", constituted as a corporation in accordance with letters patent, dated the twenty-second day of July 1954, and having its head office in the city of Beauharnois, where its office was located up to to-day, at No.110 Ellicc Street, has moved said office to 63 Ellicc Street, in the city of Beauharnois.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Beauharnois, this third day of April 1959.FRANÇOIS DORVAL.50202 President.Notice is given that \"AMaBaic Proprietors League Incorporated\u2014 La Ligue des Propriétaires d'AMaBaic Incorporée\" constituted as a corporation by letters patent dated January 21, 1959.and having ils head office at A Ma Baie, town of Pierrefonds, county of Jacques Cartier, district of Montreal, has established its office at No.4771 Pierre-Latizon Boulevard.From and after the date of this nolice, the said oflice shall be considered by the-Corporation as being its head office.Dated at Pierrefonds.this March 24, 1959.JEAN GAGNON, 50205 President.Tenders Province de Québec Les comm'ssa'hes d'écoles pour la municipalité de St-Anicet (Comté de Huntingdon) Avis public est par les présentes donné (pie des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné Aurèle Robidoux, secrétaire-trésorier, St-Anicet, comté de Huntingdon, jusqu'à 8.30 heures du soir, lundi, le 27 avril 1959, pour l'achat dc §195,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de St-5ttiicet.comté de Huntingdon, datées du 1er mai 1959 et remboursables par séries du 1er mai 1900 au 1er mai 1979 inclusivement, avec intérêt I à un taux non inférieur à AVf/( ni supérieur à Province of Quebec tlie school commissioners for the municipality of St-Anicet (County of Huntingdon) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Aurèle Robidoux.Secretary-Treasurer, St-Anicet, county of Huntingdon, until 8.30 o'clock p.m., Monday, April 27, 1959, for the purchase of SI95,000.00 of bonds of the school commissioners for the municipality of St-Anicet, county of Huntingdon, dated May 1st, 1959, and redeemable serially from May 1st, 1900 to May 1st.1979 inclusively, at a rate of not less than 4J^% or more than o%% per annum, payable semi-annually, on 1628 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Quebec, 11 avril 1959, Tome 91, N° 15 hVf/o par année, payai île scini-annucllemcnt les 1er mai et 1er novembre île chaque année.\\œ taux d'intérêt peut être le même pour toute rémission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 21 novembre 1058 \u2014 construction d'une école supérieure.Tour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er mai 1959.Le tableau (l'amortissement est le suivant: May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated November 24, 1958 \u2014 erection of a high school.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from May 1st, 1959.The table of redemption is as follows: 821.500\t00 22.5110\t00 21.000\t00 25.51 II)\t00 211.5(H)\t00 3,500\t00 3,500\t00 4,000\t00 4,000\t00 4,000\t00 4,500\t00 4.500\t00 5.000\t00 5.000\t00 5.500\t00 5.500\t00 0.000\t00 0,500\t00 0.500\t00 7,000\t00 Tableau (l'amortissement \u2014 $190.000.00 - 20 ans Année Capital 1er mai I960.x 1er mai 1901.x 1er mai 1902.x 1er mai 1963.x 1er mai 190-1.x 1er mai 1905.1er mai 1966.7.1er mai 1907.1er mai 1968.1er mai 1909.1er mai 1970.1er mai 1971.1er mai 1972.1er mai 1973.1er mai 1971.1er mai 1975.1er mai 1970.1er mai 1977.1er mai 197S.1er mai 1979.Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total dc SI24.000.00.accordé par le Secrétaire de la province et payable en cinq versements de $24,-800.00 chacune, de 1900 à 1964 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.De plus, des soumissions pourront être envoyées et seront considérées pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication -era faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Anicet.comté de Huntingdon.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligation- ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er mai 1900 inclusivement si elles sont émises à courte échéance dix ans, avant le 1er mai 1907 inclusivement si elles sont émises à courte échéance quinze ans, ou avant le 1er mai 1909 inclusivement si elles sont émises pour le terme de vingt ans; après ces dates.lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1911, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 27 avril 1959 à 8.30 heures du soir, en la salle municipale, St-Anicct, comté de Huntingdon.Table of redemption \u2014$195,000.00 \u2014 20 years Year Capital May 1st, 1900.x 821,500.00 Mav 1st, 1901.x 22,500.00 Ma'v 1st, 1902.x 24,000.00 May 1st.1903.x 25,500.00 Mav 1st, 1901.x 20,500.00 May 1st, 1965 .3,500.00 May 1st, 1900.3,500.00 Mav 1st, 1907.4,000.00 Mav 1st, 1908.4.000.00 Ma'v 1st.1969 .4,000.00 Ma'v 1st, 1970.4,500.00 Mav 1st, 1971 .4,500.00 Mav 1st, 1972.5,000.00 Ma'v 1st.1973.5,000.00 Mav 1st, 1974.5,500.00 May 1st, 1975.5,500.00 Ma'v 1st, 1970.6,000.00 Ma'v 1st, 1977.0,500.00 Mav 1st, 1978.0,500.00 May 1st, 1979.7,000.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of SI24,000.00 granted by the Provincial Secretary and payable in five instalments of S24.800.00 each, from 1900 to 1904 inclusively, will he received and applied to the service of the said loan.Moreover, tenders may be forwarded and shall'be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at St-Anicet, couidy of Huntingdon.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior to May 1st.1966, inclusively, if issued as ten-year short-term bonds, prior to May 1st, 1907 inclusively, if issued as fifteen-year short-term bonds, and prior to May 1st, 1909 inclusively, if issued for a twenty-year term, after which dates, the said bonds may.under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec 1941, be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must he accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Monday, April 27, 1959, at 8.30 o'clock p.m.in the Municipal Hall, St-Anicet, county of Huntingdon. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 11th, 1959, Vol.91, No.15 1629 Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Anicet, (Comté «le Huntingdon), ce 3 avril 1959.Le Secrétaire-trésorier, AURÈLE ROKIDOUX.St-Anicet, (Huntingdon), P.Q., Téléphone : COrvette 4-5801.50260-o Province de Québec Cité de Ste-Thérèse (Comté de Terrebonne) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné J.-.V.Filiatrault, secrétaire-trésorier.Hôtel de Ville, 36 rue Blainville Ouest, Ste-Thérèse, comté de Terrebonne, jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, le 27 avril 1959, pour l'achat dc $112,000.00 d'obligations de la cité de Ste-Thérèse.comté de Terrebonne, datées du 1er mai 1959 et remboursables par séries du 1er mai 1900 au 1er mai 1974 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à ¦\\l2% ni supérieur à 5Vf/c par année, payable scini-annuellment les 1er mai et 1er novembre de chaque année.I/' taux d'intérêt peut être le même pour toute rémission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt N° 123 X.S.\u2014consolidation dc dettes.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er mai 1959.Ix- tableau d'amortissement est le suivant: Tableau (l'amortissement \u2014 $112.000.00 \u2014 15 ans Année Capital 1er mai 1900.S5.000.00 1er mai 1901.5,500.00 1er mai 1902.5.500.00 1er mai 1903.6.000.00 1er mai 1901.0,500.00 Ire mai 1965 .0.500.00 1er mai 1966.7,000.00 1er mai 1907.7.500.00 1er mai 1968.7.500.00 1er mai 1909.8.000.00 1er mai 1970.8.500.00 1er mai 1971.9,000, (M) 1er mai 1972.9.500.00 1er mai 1973.10.000.00 1er mai 1974.10,000.00 De plus, des soumissions pourront être envoyées et seront considérées pour des obligations à courte échéance dix ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des deux termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Ste-Thérèse, comté , de Terrebonne.Lé capital et les intérêts sont payables à tontes Iles succursales dans la province de Qué'bec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er mai 1906 inclusivement si elles sont émises à courte échéance dix ans, ou avant le 1er mai 1967 inclusivement si belles sont émises pour le terme dc quinze ans; après ces dates, lesdites obligations pourront, sous R'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus Vie Québec, 1941, être rachetées par anticipation.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.St-Anicet, (County of Huntingdon), this April 3, 1959.AURÈLE ROBIDOUX, Secretary-Treasurer.St-Anicet, (Huntingdon), P.Q., Telephone: COrvette 4-5801.50260 Province of Quebec City op Ste-Thérèse (County of Terrebonne) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Ponds\" will be received by the undersigned J.-A.Filiatrault, Secretary-Treasurer, City Hull, 30 Blainville West.Ste-Thérèse.county of Terrebonne, until 8.00 o'clock p.m.Monday\", April 27, 1959 for the purchase of an issue of Si 12.000.00 of bonds for the city of Ste-Thérèse, county of Terrebonne, dated May 1st, 1959.and redeemable seriallv from May'1st.1900 to May 1st.1974 inclusively, with interest at a rati- not less than 4V£9?nor more than 5J^% per annum payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law Xo.123 X.S.\u2014 consolidation of debts.'For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from May 1st, 1959.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $112,000.00 \u2014 15 years Year Capital Mav 1st, 1900 .85.000.00 Mav 1st.1961 .r.5,500.00 Mav 1st.1902.5.500.00 Mav 1st, 1903 .0.000.00 Mav 1st, 1964 .0.500.00 Mav 1st.1905 .0.500.00 Mav 1st.1900 .7.0(H).00 Mav 1st.1907 .7,500.00 Mav 1st.190*.7,500.00 Mav 1st.1909 .8.000.00 Mav 1st, 1970 .8,500.00 Mav 1st, 1971 .0.000.00 Mav 1st, 1972 .9.500.00 Mav 1st, 1973 .10.000.00 Mav 1st.1971 .10.000.00 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term.However, tenders shall be considered for one of the two-terms only.Adjudication shall hi- made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Ste-Thérèse, county of Terrebonne.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec, of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the head oflice of the said bank at Toronto.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior to May 1st, 1900 inclusively, if issued as ten-year short-term bonds, prior to May 1st, 1967 inclusively, if issued as fifteen-year short-term bonds, after which dates the bonds are, under authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec.1911.subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, 1030 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 avril 1959, Tome 91, N° 15 en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant «le l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment «le leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance «lu conseil qui sera tenue lundi, le 27 avril 1959, à S.00 heures «lu soir, en l'Hôtel de Ville, 30 rue Blainville Ouest, Ste-Thérèse, comté de Terrebonne.Ix?conseil se réserve le droit «le n'accepter ni la plus haute ni aucune «les soumissions.Ste-Thérèse, (Comté de Terrebonne), ce 3 avril 1959.Le Secrétaire-trésorier.J.-A.FILIATRAULT.Adresse postale: Hôtel «le Ville, C.P.90, 30 rue Blainville Ouest, Ste-Thérèse, (Terrebonne).P.Q.Téléphone : TAlbot 3-9521.50201 -o Province de Québec Cité nr.Dorval (Comté «le Jacques-Cartier) Avis public est par les -présentes donné que «les soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné Armand DelTorchio, greffier, Hôtel de Ville, 40 avenue Martin, Dorval, comté de Jacques-Cartier, jusqu'à 9.00 heures du soir, mercredi, le 29 avril 1959, pour l'achat «le §528,000.00 d'obligations de la cité de Dorval, comté dc Jacques-Cartier, datées «lu 1er mai 1959 et remboursables par séries du 1er mai 1900 au 1er mai 1979 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4}^% ni supérieur à 5,/£% par année, payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre «le chaque année.Ix» taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements d'emprunts Nos 431 - 853,000.00.construction «le trottoirs et «le chaînes «le rues; 438 \u2014 SOI.000.00, éclairage de rues; 440 \u2014 S134.000.00.travaux d'améliorations dans les parcs et les terrains de jeux: et résolution du 4 mars 1959\u2014 $280,000.00, travaux d'aqueduc et d'égoûts.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter «lu 1er mai 1959.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $528,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 1900.SI8,000.00 1er mai 1961.18,500.00 1er mai 1902.20,000.00 1er mai 1903.20,500.00 1er mai 1964 .21,500.00 1er mai 1905.22,500.00 1er mai 1906.23,500.00 1er mai 1967.25.500.00 1er mai 1968.26,500.00 1er mai 1909 .28,000.00 1er mai 1970.21,500.00 1er mai 1971.23,000.00 1er mai 1972.24,000.00 1er mai 1973.25,500.00 1er mai 1974.26,500.00 1er mai 1975.28.500.00 1er mai 1976.30,000.00 1er mai 1977.31,500.00 at par, at any interest maturity date; however, in case of partial rcf the above mentioned line, and bounded thus: at one end by the royal road, on one siele.by lot eight, and on the other two sides by the land e>f Appolinaire Goulet, or representatives, circumstances and dependencies; the above measures we-re taken accoreling to French feet.\" Item (A) shall be put up lor sale te» the last and highest bidder with rents as a burden thereon ami the Church apportionments which may exist.Titles ami certificates may be examined at all times by applying to the office eif the un» elersigneel Trustees.This sale is made in accordance with articles 716, 717 and 719-A e>f the Code of Civil Procedure and also article 55 e>f the Bankruptcy Act.This sale is the equivalent of a Sheriff sale.Conditions of payment: Cash.Quebec, Aprii 9, 1959.R.ERNEST LEFAIVRE & RENÉ LEFAIVRE, Trustees.Offices: 111, Mountain Hill.Quebec.50282-15-2 Canada, Province de Québec, district de Québec, Cour Supérieure (En matière de faillite), N° 6102-F.Dans l'affaire de la faillite de: Albéric Régin.garagiste, St-Évariste Station, comté ele Frontenac, débiteur.AVIS DE VENTE Avis est par les présentes elonné (pie: MERCREDI, le TREIZE MAI 1959, à DIX heures a.m., seront vendus par encan public, à la porte de l'église de la paroisse de Notre-Dame de la Guadeloupe, comté de Frontenac, les immeubles ci-après décrits, savoir: Item A) \"Un terrain de forme irrégulière, faisant partie du lot numéro vingt-cinq A (25A) du cadastre pour le rang A du canton dc Forsyth, comté de Frontenac, étant maintenant, suivant le nouveau cadastre, une partie du lot (25A-14) Canada, Province of Quebec, district of Quebec, Superior Court (Sitting in Bankruptcy) No.0102-F.In the matter of the bankruptcy of: Albéric Régin, garage-keeper, St.Ev'ariste, Station, county of Frontenac, debtor.NOTICE OF SALE Notice is hereby given that: WEDNESDAY, the THIRTEENTH day of MAY 1959, at TEN o'clock a.m., shall be sold by public auction, at the door of the church of the parish of Notre-Dame de la Guadeloupe, county of Frontenac, the immoveables hereinafter described, to wit: Item A) \"A piece of land of irregular shape, forming part of lot number twenty-five A (25A) of the cadaster for range A of the township of Forsyth, county of Frontenac being presently, according to the new cadaster, a part of lot QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec April nth, 1969, Vol.91, No.16 1(535 vingt-cinq-A, quatorze, «lu susdit cadastre, mesurant, en froid, au chemin public, appelé route \"Lambton\", environ quarante-deux pieds, quatre-vingt-quatre à quarante-quatre pieds quatre-vingt-quatre (12.si ;'i 44.84) de largeur, soit tonte la largeur qu'il peut y avoir à partir du ruisseau de la Station à aller au terrain de M.C.E.Dallaire; sur le côté nord dudit emplacement (C.F.Dallaire voisin) en gagnant la profondeur, ledit terrain en ligue perpendiculaire au chemin s'avançan! sur une distance de vingt pieds (2()') du coin nord-ouest de la bâtisse et également de vingt pieds (20') du coin sud-ouest de la bAlisse bornant ainsi à l'ouest au terrain restant à la venderesse.I.e tout d'après bornage judiciaire, dont jugement à intervenir, cause numéro 10.087.étant actuellement devant la Cour du Banc du Roi, ceci connu de la partie de seconde part.Avec bâtisse dessus construite.Avec mise- à prix «le $19,000.00.L'acquéreur devant respecter le bail existant en faveur «le la Banque Canadienne de Commerce.\" Item B) \"In emplacement de terrain à la Guadeloupe, étant partie du lot 2-1-B.du cadastre pour le rang A du canton Forsyth, du comté de Frontenac, ayant front sur la route Nationale N° 28, et mesurant cent cinquante pieds (150') de largeur en front et à la profondeur sur une profondeur «le trois cent pieds (300'), borné en front par la route \\° 28; dans la profondeur à l'ouest au terrain de Madame Paul Gilbert OU représentant, d'un côté au nord au terrain de madame Paul Gilbert au représentant, et de l'autre côté au sud au terrain ci-après désigné.Avec bâtisse servant de garage et autres dépendances.\" Rem C) \"Un emplacement de terrain voisin de celui ci-dessus, mesurant cent pieds (100') de largeur en front et à la profondeur sur une profondeur de trois cent pieds (300'); borné en front par la route N° 28; à la profondeur à l'ouest au terrain de Madame Paul Gilbert OU représentants, d'un côté au nord au terrain plus haut mentionné et de l'autre côté au sud au terrain de Madame Paul Gilbert ou représentants.Le tout avec la maison dessus construite, circonstances et dépendances; cet immeuble est aussi connu comme étant partie 24-B du rang A de Forsyth.\" Item D) \"Un morceau de terrain à St-Evariste étant partie des lots numéros vingt-quatre A et vingt-quatre C (Pties 21A-24C) du cadastre pour le rang sept (rg.VII) du canton Forsyth, comté de Frontenac, de figure irrégulière, et compris entre les points indiqués par les lettres \"A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-A\" sur un plan annexé à la minute des présentes pour aider à la description, lequel est reconnu véritable et signé par les parties et le notaire soussigné pour faire partie «le cet acte et mesurant environ deux arpents de largeur en front au chemin public entre les points \"A et I\", environ cinq arpents de profondeur entre les points \"A et B\".dans la ligne du terrain de Lucien Grégoire; à partir du point \"B\" la ligne du terrain vendu se trouve limité par la clôture actuelle qui est irrégulière, et passe par les points \"C-D\" jusqu'au point \"F\", de ce point le terrain vendu laisse la ligne de la clôture actuelle pour élargir d'une largeur de soixante pieds au point \"F\" (mesuré de la clôture actuelle indiquée par le point \".I\" au point \"F\") du point \"F\" la ligne se continue jusqu'au point \"G\" sur une longueur d'environ quatre cent vingt pieds et du point \"G\" au point \"H\" le terrain mesure trente pieds (soit trente pieds à partir de la clôture actuelle \"H\" jusqu'au point \"G\") le terrain entre le point \"II\" et le point \"I\" mesure une (25A-14) twenty-five A.fourteen, of above cadaster, measuring, in front, on the publier highway, called \"Lambton\" Road, some fe>rty-two feet, eighty-four te» forty-four feet, eighty-four (42.84 to 44.84) in width, i.e.the whole width that may exist as from the Station Broe>k to the land of Mr.C.P.Dallaire: on the north side of the said emplacement (C.F.Dallaire neighbour) leading to the depth, the- saiel land in a line perpeiulicular to the road ale>ng a distance of twenty feet (20') from tlie- northwesterly ee>rm-r of the buileling ami a!se> twenty feet (20') fre»m the send h westerly e-e>rne-r e»f the building thus bounded westcrby by the- land remaining te> the vendor.All of which according to legal boundaries, which a judgment te» intervene; cause number 19,687, is presently before the Court e»f King's Bench, e>f which the parly e>f the second part is aware.With building I hereon erected.With upset prier in the amount e»f $10.000.00.The purchaser having to respect the existing lease in fave>ur e»f the Canadian Bank e>f Com-ine-re-e.\" Item B) \"An emplacement of land at La Guadeloupe, being part of lot 24-B, of the cadaster for range A, township of Foèsyth, county of Frontenac, fronting em National Highway No.28, ami measuring one hundred ami fifty feet (1500 wide in front ami in depth along a depth of three hundred feet (300'), bounded in front by route Ne>.28; at the depth westerly by the lanel of Mrs.Paul Gilbert or representatives; on one side north-e-rly by the lanel e»f Mrs.Paul Gilbert or representative-, ami e»n the other side southerly by the land hereinafter described.With buileling serving as a garage ami other dependencies.\" Item C) \"An emplacement of land adjoining that above, measuring one hundred feet (1000 wide in fron ami depth by a depth of three hundred feet (300'); bounelcel in front by route No.28; in depth westerly by the land of Mrs.Paul Gilbert e>r representatives, on one sie|e\\ northerly, by the lanel mentioned hereinabove- ami on the other side, southerly, by the land «»f Mrs.Paul (iilbe-rt e>r representatives.All e»f which with house thereon e-rectcd, circumstances ami dependencies; this immoveable is aise» known as being part 2-1-B, range A of Forsyth.\" Item D) \"A piece- e)f land at St.Evariste being part e»f le»t numbers twenty-four A ami twenty-four C (Pts.2IA-24C) of the cadaster for range seven (rg.VII) etf the township e»f Feirsyth, county e»f Frontenac, etf irregular shape ami comprised between the peiints indicated by letters \"A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-A\" on a plan hereby annexed te> the deed in order te> help with the eleseTiption.which plan is kne»wn as being authentic and signed by the parties ami the undersigned mdary in etreler to fe>rm part e»f saiel ele-ed ami measuring some two arpents wide in front ale»ng the public highway between points \"A ami I\", about five arpents in depth between points \"A and B\", along the line of the lanel e>f Lucien Grégoire; as from point \"B\" the line e)f the land sold is bonnele'el by an e-xisting fence e>f irregular shape, and passes alenig points \"C-D\" as far as point \"E\", from said point the land sold, breaking away from the present fence line ami wideing out in a width of sixty feet at point \"F\" (measured from the existing fence indicated by point \".I\" up to point \"F\") fremi point \"F\" the line extends as far as point \"G\" along a length of some four hundred ami twenty feet ami from point \"G\" to point \"H\" the lanel measures thirty fe-e-t (i.e.thirty feet as from the existing fe-nce- \"II\" as far as point \"(i\").the- lanel between point \"II\" and 1636 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, II avril 1959, Tome 91, JV° 15 distance d'environ trois cent pieds; le tout borné en front pur le chemin public, d'un côté au terrain dc Lucien Grégoire (23B), à la profondeur et de l'autre cé>té au terrain restant au vendeur.\" Les items (A), (B), (C), (D), seront offerts en vente au plus haut et dernier enchérisseur à charge des rentes et répartitions d'église qui peuvent exister, ainsi que sujets aux servitudes actives et passives pouvant exister.IiCS titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressant aux bureaux des syndics soussignés.Cette vente est faite conformément aux articles 710.717 et 710-A du Code de Procédure Civile et aussi à l'article 55 de la lx>i de faillite.Cette vente équivaut à la vente faite par le shérif.Conditions dc paiement: argent comptant.Québec.9 avril 1959.Les Syndics.R.ERNEST LEFAIVRE & RENÉ LEFAIVRE.111, Côté de la Montagne.Québec.50283-15-2-o point \"I\" measures in distance some three hundred feet; all of which bounded in front by the public highway, on one side by the land of Lucien Grégoire (23B), at the depth and on the other side by the land remaining to the vendor.\" Items (A), (B).(C).(D), shall be offered for sale to the last and highest bidder with rents as a charge thereon and church apportionments if any.as well as subject to the servitudes both active and passive which may exist.Titles and certificates may be examined at all times by applying to the offices of the undersigned trustees.This sale is made in accordance with articles 710.717 and 719-A of the Code of Civil Procedure and also article 55 of the Bankruptcy Act.This sale is equivalent to a sale by Sheriff.Conditions of payment: cash.Quebec.April 9.1959.R.ERNEST LEFAIVRE & RENÉ LEFAIVRE.Trustees.111 Mountain Hill.Quebec.50283-15-2 Canada, Province de Québec, district de Québec, N° 6113-F.Cour Supérieure (En Matière de Faillite).Dans l'affaire de la faillite de : Willy Taylor, voyageur, 129, Mainguy, Ste-Foy, ci-devant hôtelier à St-Adelphe, comté de Champlain y exploitant l'Hôtel Royal, Route de la Station, débiteur.AVIS DE VENTE Avis est par les présentes donné que JEUDI, le TRENTIÈME jour d'AVRIL 1959, à DEUX heures p.m.sera vendu par encan public, à la porte dc l'église de la paroisse de St-Adelphe, comté de Champlain, l'immeuble ci-après décrit, savoir: \"Un emplacement situe dans le village de St-Adelphe faisant partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro sept cent vingt-trois (Ptie 723) du cadastre de la paroisse de St-Sta-nislas, mesurant cinquante pieds de largeur sur cent pieds de profondeur, le tout à la mesure anglaise; borné comme suit: en front par le chemin public, en profondeur et d'un côté, vers l'est par dame Onésime Mongrain, et de l'autre côté, vers l'ouest, par Benjamin Roberge; avec une maison servant d'Hôtel et autres bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.\" Cet item sera offert en vente au plus haut et dernier enchérisseur à charge des rentes et répartitions d'église qui peuvent exister.Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressant aux bureaux des syndics soussignés.Cette, vente est faite ceonformément aux articles 710, 717 et 719-A du Code de Procédure Civile et aussi à l'article 55 de la Loi de Faillite.Cette vente équivaut à la vente faite par le Shérif.Conditions de paiement: argent comptant.Quelle, 23 mars 1959.Les Syndics, R.ERNEST LEFAIVRE & RENÉ LEFAIVRE.111, Côte de la Montagne, Québec.50160-13-2-O Canada, Province of Quebec, district of Quebec, Superior Court (Sitting in bankruptcy) No.0113-F.In the matter of the bankruptcy of : Willy Taylor, traveller, 129 Mainguy, Ste-Foy, heretofore hotel-keeper at St-Adelphe, county of Champlain therein operating the \"Hôtel Royal,\" Station Road, debtor.NOTICE OF SALE Notice is hereby given that THURSDAY, APRIL THIRTIETH, 1959, at TWO o'clock p.m., shall be sold by public auction at the church door of the parish of St-Adclphc, county of Champlain, the immoveable hereinafter described, to wit: \"An emplacement situated in the village of St-Adelphe forming part of lot of land known and designated under number seven hundred and twenty-three (Pt.723) of the cadaster for the parish of St-Stanislas, measring fifty feet in width by one hundred feet in depth, the whole by English measure; bounded as follows: in front by the public highway, in depth and on one side, on the East, by dame Onésime Mongrain, and on the other side, on the west, by Benjamin Roberge; with house serving as a hotel and other buildings thereon erected, circumstances and dependencies.\" This item shall be offered for sale to the highest and last bidder subject to the rents and church distributions which may exist.Titles and certificates may be examined at all times by applying to the offices of the under-signecftrustees.This sale is made pursuant to articles 710, 717 and 719-A of the Code of Civil Procedure and also to article 55 of the Bankruptcy Act.This sale is equivalent to that made by the Sheriff.Conditions of sale: cash.Quebec, March 23, 1959.R.ERNEST LEFAIVRE &' RENÉ LEFAIVRE, Trustees.Ill, Mountain Hill, Quebec.50100-13-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 11th, I960, Vol.91.No.16 Vente par licitation Canada, Province de Québec, district d'Arthabaska, Cour Supérieure, N° 13,744.Jacques Constant, journalier de Victoriaville, demandeur, vs Alfred Constant, cultivateur d'Arthabaska, défendeur, et Marcel Constant, employé tie la banque de Victoriaville, tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur aux enfants mineurs Suzanne, Lise, Jean-Paulet Colette Constant, «le Victoriaville et d'Arthabaska, Denise Constant, ménagère de Victoriaville, épouse de Oscar Croteau, journalier de Victoriaville, et ledit Oscar Croteau, pour autoriser sadite épouse aux fins des présentes, Madeleine Constant, célibataire majeure usant de ses droits, couturière d'Arthabaska, mis-en-cause.AVIS DE LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure siégeant à Arthabaska dans le district d'Arthabaska.le 7 avril 1959 dans une cause dans laquelle Jacques Constant, journalier dc Victoriaville est demandeur, ordonnant la licitation d'un certain immeuble désigné comme suit: \"Une terre à prendre dans la partie centrale du lot N° 6 du 2ième rang du canton d'Arthabaska, contenant 5 arpents de front, plus ou moins, sur la profondeur du rang, connue et désigné' au cadastre officiel d'Astliabaskaville, sous les numéro dix-huit et dix-neuf (18-19) prenant du côté sud-est à Alexandre Pellerin ou représentants et du côté Nord-Ouest à Léon Couture, avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances,\" l'immeuble ci-dessus décrite sera mis à l'enchère et adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur, le VINGT-TROISIÈME jour de MAI 1959 à DIX heures du matin, ('our tenante, dans la salle d'audience du palais de Justice d'Arthabaska, sujet aux charges clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au greffe du Protonotaire de ladite cour et que toutes oppositions afin d'annuler, afin de charger ou afin de distraire à ladite licitation, devra être déposée au greffe du Protonotaire à ladite cour au moins douze jour avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et que toutes oppositions afin de conserver, devra être déposée dans les six jours après l'adjudication et à défaut, par les parties de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par le présent, elles seront forcloses du droit de le faire.Victoriaville.le 8 avril 1959.Les Procureurs du demandeur, 50278- 15-2-o TROTTIER & MOISAN.Vente pour taxes Ville de Senneterre Avis de vente d'immeubles Avis public est par les présentes donné que les propriétés immobilières ci-après mentionnées et plus spécialement désignées dans une cédule déposée dans mon bureau le 17 mars 1959, seront vendues par moi, à l'Hôtel de Ville de Senne-terre, Abitibi Est, province dc Québec, MERCREDI, le TREIZIÈME jour de MAI 1959.Sale by Licitation Canada, Province of Quebec, district of Arthabaska, Superior Court, No.13,744.Jacques Constant, laborer of Victoriaville, plaintiff, vs Alfred Constant, farmer of Arthabaska, de-fendant, and Marcel Constant, employee of the bank at Victoriaville, as much personally as in her quality of tutor for the minor children, Suzanne, Lise, Jean-Paulet Colette Constant, of Victoriaville and of Arthabaska, Denise Constant, housewife of Victoriaville, wife of Oscar Croteau, laborer, of Victoriaville, and the said Oscar Croteau, to authorize his said wife for these presents, Madeleine Constant, spinster of full age in use of her rights, seamstress of Arthabaska.mis-en-cause.NOTICE OF LICITATION Notice is given that in virtue of a judgment of the Superior Court sitting at Arthabaska in the district of Arthabaska, on April 7, 1959, in a case in which Jacques Constant, laborer of Victoriaville is plaintiff, ordering the licitation of a certain immoveable designated as follows: \"A farm to be taken in the central part of lot No.6 of the 2nd range of the township of Arthabaska, containing 5 arpents in frontage, more or less, on the depth of the range, known and designated on the official cadaster of Artha-baskaville, under numbers eighteen and nineteen (18-19) touching on the southeast side property of Alexandre Pellerin or representatives and on the northwest side, property of Léon Couture, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies,\" the immoveable above described will be sold by auction and adjudged to the highest and last bidder on the TWENTY-THIRD day of MAY, 1959, at TEN o'clock in the morning, Court sitting in the audience chamber of the Court House of Arthabaska, subject to the charges, clauses and conditions mentioned in the list of charges filed in the office of the prothonotary of the said Court; and any opposition to annul, to secure charges or to withdraw to be made to the said licitation must be filed in the office of the prothonotary of the said Court at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication and any opposition for payment must be filed within six days following adjudication and failing the interested parties to file the said opposition within the delays hereby prescribed, they shall be foreclosed from so doing.Victoriaville.April 8, 1959.TROTTIER & MOISAN, 50278-15-2 Attorneys for plaintiff.Sale for Taxes Town ok Senneterre Notice of sale of immoveables Public notice is hereby given that the immoveable properties hereinafter mentioned and more particularly described in a schedule filed in my office on the 17th of March 1959, will be sold by me at the Town Hall of Senneterre.Abitibi East.Province of Quebec, on WEDNESDAY.MAY THIRTEENTH.1959, at 1638 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec II avril 1959, Tome 91, N° 16 à DIX heures a.m., à raison d'une réclamation TEN o'clock in the forenoon upon claim by the de la Ville de Senneterre pour taxes ct contri- \u2022 Town of Senneterre for annual or special real butions foncières ou spéciales ou pour arrérages estate taxes and assessments or for arrears of de taxes quelconques, à moins que lesdits arré- consolidated taxe, unless the said arrears and rages et les frais en soient payés au préalable.costs are paid in advance; Nom du propriétaire Name f proprietor Bouclier à Paré Enrg.Bouclier, Dame Fernande.Bouclier, Dame Ritfl.Gagnoii, Thomas.Giguère, Rosario.Lamarche.Marcel.Lchlond, Conrad.- Lemieux, Lionel SUOO.-QSl.Meilleur, Joan-Paul.Paré, Albert.Paré, Dame Fernande.Superficie Area 7.000'.6,500'.6,500'.7.000'.7.000'.0,500'.7.000'.7,000'.6,500'.6,500'.13.000'.Lots numéros Lot numbers 0.13.0.4.:.0.19.0.3.1 & 2.Numéros du oadost ro Cadastral numbers Bloc -Block 77.4.70.96.D3____ st.76.95.77.70.5.Taxes\tTaxes\t munie.\tscolaires\t \u2014\t\u2014\tTotal Munie.\tSchool\t taxes\ttaxes\t \t?84.16\tS 84.15 142.01\t71.10\t213.1 1 134.52\t7S.00\t212.52 112.37\t69.25\t211.02 033.28\t333.15\t966.43 304.41\t79.25\t383.00 180 50\t32.45\t212.95 100.01\t89, 16\t219.10 172.94\t\t172.94 97.50\t17.75\t115.25 197.21\t70.95\t274.10 Senneterre, 17 mars 1959.I-e Sécrétaire-1réstnier.(Sceau) ZENON BACON.501G1-13-2-o Senneterre, March 17.1050.ZENON BACON, (Seal) Secretary-Treasurer.50161-132-o VENTES PAR SHÉRIFS SHERIFFS' SALES AVIS PUBLIC, est par le présent donné que PUBLIC NOTICE, is hereby given that the les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés undermentioned LANDS and TENEMENTS out été saisis ct seront vendus aux temps et lieux have been seized, and will be sold at the respect-respectifs, tels que mentionnés plus bas.ive times and places mentioned below.ABITIBI Canada \u2014 Province de Québec District d'Abitibi ABITIBI Canada Province of Quebec District of Abitibi Cour de l'Echiquier ( TVVNS L'AFFAIRE Court of the Exchequer / TN THE MATTER du Canada, )U DE LA LOI DE of Canada.J A OF THE INCOME N° 151.828.\\ L'IMPOT SUR LE [ REVENU ct amendements et DANS L'AFFAIRE DE ADRIEN BIBEAULT, de Rochebcaucourt, du comté d'Abitihi-Est, Province dc Québec.No.151.828.Vl'AX ACT ami (.amendments and IN THE MATTER OP ADRIEN BIBEAULT.of Rochebcaucourt.of the county of Abitibi-East, Province of Quebec.AVIS DE VENTE Les droits acquis sur l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro vingt-deux (22) du rang X du canton Rochebcaucourt, comté d'Abitib-Est, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendus à la porte de l'église paroissiale de Rochebcaucourt, comté d'Abitibi-Est, le VINGT-NEUVIÈME jour d'AVRIL 1959 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif d'Abitibi, Bureau du Shérif, .1.A.GAUTHIER.Amos, 10 mars 1959.50110-12-2-o NOTICE OF SALE The rights acquired on the immoveable known and designated as being lot number twenty-second (22) of range X of the township of Rochebcaucourt, county of Abitibi-East, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of Rochebcaucourt.countv ol Abitibi-East, on the TWENTY-NINTH day of APRIL, 1959, at TWO o'clock in the afternoon .).A.GAUTHIER.Sheriff's Office.Sheriff of Abitibi.Amos, March 16, 1959.50116-12-2 BEAUHARNOIS Fieri Facias de Bonis et de Terris District de Beauharnois Cour Supérieure, i \"D OLAND POUPARD, no-Montréal & ) L^- taire, domicilié à Ste-Beauharnois, \\ Martine, district de Beau-N° 428 464.f harnois, demandeur, et MARCEL PILON, domicilié à 9,715 Basilc-Routhier, Montréal, district de Montréal, défendeur.BEAUHARNOIS Fieri Facias de Bonis et de Terris District of Beauharnois Superior Court, ( \"D OLAND POUPARD, no-Montreal & 1 tary, domiciled at Ste.Beauharnois, \\ Martine, district of Beauhar-No.428 464.I nois, plaintiff and MARCEL PILON, domiciled at 9,715 Basilc-Routhier, Montreal, district of Montreal, defendant. QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, Quebec, April tlth, 1959, Vol.91, No.15 1639 A savoir: \"Un emplacement sis et situé en ladite paroisse de St-Anicet, connu et désigné au plan et dans le livre de renvoi officiels de cette paroisse et de celle de Ste-Barhe, comme étant partie du lot numéro trois cent soixante-sept (Pte N° 367) mesurant environ cent dix pieds de largeur, par la profondeur dudit lot, c'est-à-dire, quatre-vingt-treize pieds de profondeur, borné: à l'est par la rue de la Fabrique, au sud par le lot N° 368, à l'ouest par le lot N° 370, et au nord par le résidu dudit lot N° 367.Un autre emplacement sis et situé au même lieu, connu ct désigné au plan et dans le livre de renvoi officiels susdits, comme étant partie du lot numéro trois cent soixante-dix (Pte N° 370), mesurant cent trente-cinq pieds dc largeur par la profondeur dudit lot, soit quatre-vingt-treize pieds, borné: à l'est par le lot N° 307, au sud par le lot N° 369, à l'ouest, par la rue St-Miche, et au nord par le résidu dudit lot N° 370.Avec ensemble les constructions édifiées sur ces deux lots.\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Anicet, dit district, le VINGT-TROISIÈMK jour d'AVRIL, 1959, à DIX heures de Pavant-midi.Le Shérrf, Bureau du Shérif, ERNEST POIRIER.Salaberry de Valleyfield, ce 13 février 1959.50104-12-2-O BEDFORD Canada Province de Québec District de Bedford ( W7TNDSOR ICREDIT N° 402 549.J W UNION LIMITED, l un corps politique et incorporé dûment constitué en corporation en vertu de la Loi des Syndicats Coopératifs de Québec, ayant son siège social et principale place «l'affairés en les cité et «listrict.de Montréal, vs DE STELLA PASZEK, veuve de feu Stanley Tomaszewski, domiciliée auparavant en les cité et district de Moidréal et actuellement dc Shefford-Ouest, district de Bedford.Une ferme connue et décrite aux plan cadastral ct livre de renvoi du canton de Brome, comté de Brome, comme étant le lot numéro cinq cent quatre-vingt-quatorze (594) et la demie sud du lot numéro cinq cent quatre-vingt-treize (Yi S.593), contenant tous ensembles soixante-cinq acres de terres en superficie, plus ou moins, tel qu'actuellement clôturée, avec les constructions dessus érigées et faites; et aussi y compris dans cette vente tous les instruments aratoires et outils se trouvant sur ladite ferme.Avec les constructions dessus érigées et faites.Le vendeur, cependant, se réserve pour lui-même ou ses représentants, les vingt-sept (27) billots déjà coupés qui sont dans le pâturage.\" Pour être vendue à la porte de l'église paroissiale de St-François-Xavier de Wcst-Shefford.district de Bedford, JEUDI, le QUATORZIÈME jour de MAI 1959.à DEUX heures de l'après-midi.Ix?Député Shérif, Bureau du Shérif, AX TON IN BOURASSA.Sweetsburg.3 avril 1959.50252-15-2 CUICOUTIMI Fieri Facias District de Chicoutimi Cour Supérieure.( JULES GAUTHIER, notai-.\\'° 25,398.IJ re de Jonquière, demandeur; vs GÉRARD ^TREMBLAY, 53, rue De La Montagne, Jonquière, P.Q.défendeur.To wit: \"An emplacement lying and situate in said parish of St.Anicet, known and designated on the official plan and book of reference of said parish and that of Ste.Barbe, as being part of lot number three hundred and sixty-seven (P.No.307) measuring some one hundred and ten feet in width by the depth of the said lot, that is, ninety-three feets of depth, bounded: easterly by de la Fabrique Street, southerly by lot No.368, westerly by lot No.370, and northerly by the residue of said lot No.307.Another emplacement lying and situate in the same locality, known and designated on the official plan and book of reference mentioned above, as being part of lot number three hundred and seventy (P.No.370) measuring one hundred and thirty-five feet in width by the depth of said lot, i.e.ninety-three feet, bounded: easterly by lot No.307, southerly by lot No.309, westerly by St.Miche Street, and northerly by the residue of said lot No.370.Together with the buildings erected on said two lots.\" To be sold at the door of the parochial church of St.Anicet, said district, the TWENTY-THIRD day of APRIL, 1959, at TEN o'clock in the forenoon.ERNEST POIRIER, Sheriff's Office, Sheriff.Salaberry de Vallevfield.this February 13, 1959.50104-12-2 BEDFORD Canada \u2014 Province of Quebec District of Bedford /\\\\7\"INDSOR CREDIT No.102 549.-J VV UNION LIMITED, \\ a body politic and corporate, duly incorporated in virtue of the Quebec Co-Operative Syndicate's Act.having its head office and principal place of business in the city and district of Montreal, vs DE STELLA PASZEK.widow of the late Stanley Tomaszewski, previously residing in the city and district of Montreal, and presently of West Shell'ord, district of Bedford.\"A farm known and described upon the official cadastral plan and in the book of reference for the township of Brome, count y of Brôrae, as being the lot number five hundred and ninety-four (594), and the south half of lot number five hundred and ninety-three (S.593), containing all together sixty-live acres of land in superficies, more or less, as actually fenced in, with the buildings thereon erected and made; and also included in this sale all farm implements and tools being on said farm.With the buildings thereon erected and made.The vendor, however, reserves for himself or his representatives, twenty-seven (27) logs, already cut.which are in the pasture.\" To be sold at the parochial church door of St-François-Xavier de Wcst-Shefford, district of Bedford, THURSDAY the FOURTEENTH day of MAY, 1959, at TWO o'clock in the afternoon.AX TOXIN BOURASSA, Sheriffs Office.Deputy Sheriff.Sweetsburg.April 3, 1959.50252-15-2-O CUICOUTIMI Fieri Facias District of Chicoutimi Superior Court, ( JULES GAUTHIER, nota-No.25,398. (Première insertion: le 21 mars 1959] SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Bonis et de Terris District de St-François Cour de Magistrat, (t A CITÉ DE MAGOG, Magog, ) *-* corporation municipa-N° 16 580- \\ le dûment incorporée, ayant i son siège social à Magog, district de St-François, demanderesse, vs DAME ANTOINETTE PERRIER, fille majeure et usant de ses droits, de la cité de Y/ngog, district de St-François, défenderesse.\"Le lot 1220 au plan officiel et livre rie renvoi de la cité de Magog; \u2014 lot de forme irrégulière borné au nord-est par le lot 1219, au sud-ouest par le lot 1221 et au sud-est par le lot 1218 et au nord-ouest par la rue publique.Le tout contenant une superficie rie 3959 pieds, mesure anglaise.\" Pour être vendu à la porte rie l'église paroissiale rie Ste-Margucrite-Marie de Magog, MERCREDI, le TREIZIÈME jour rie MAI 1959.à DIX heures a.m.Le Shérif.Bureau du Shérif, JOSEPH LABRECQUE.Sherbrooke, ce 7 avril 1959.50276-15-2-0 [Première insertion, le 11 avril 1959] Index de la Gazette officielle de Québec, N° 15 Action en séparation de biens: Bélisle vs Portier.1009 Arrêtés en Conseil: 289-A \u2014 Construction, région de St-Hyacinthe.1609 289-C \u2014 Fer et bronze d'ornementation, région rie Mont réal.1612 Avis aux intéressés: 1577 a business office at Roberval, district of Roberval, plaintiff, vs RENÉ GRENIER & DAME MARIE-JEANNE ROUSSEAU, widow of the late Raoul Grenier, both of St-Félicien, defendants.\"An emplacement lot situated in the municipality of the town of St-Félicien, measuring fifty-nine feet (59') in width along an average length of two hundred and ten feet (210'), known and designated under number nine-one, cadastral subdivision of the original lot number two-A (No.2-A-9-1) of the first (1) range, of the official cadaster of the township Demeules, also comprising the store-residence thereon erected, the sheds and appurtenances and dependencies\", undivided property of René Grenier, and of rlanic Marie-Jeanne Rousseau, widow of the late Raoul Grenier, of St-Félicien, according to judgment rendered.\" To be solrl at the church door of the parish of St-Félicien, countv of Roberval, on the TWENTY-THIRD (23) day of APRIL, 1959.at TWO o'clock in the afternoon.LÉON-MAURICE LAVOIE, Sheriff's Office, Sheriff of Court House.the rlistrict of Roberval.District of Roberval, March 14, 1959.50105-12-2 [First insertion: March 21, 1959] ST.FRANCIS Fieri Facias de Bonis et de Terris District of St.Francis Magistrate's Court, ( rPHE CITY OF MA-Magog, ) *\u2022 GOG, municipal cor-No.16 580- \\ poration duly incorporat-\\ ed, having its corporate seat at Magog, rlistrict of St.Francis, plaintiff, vs DAME ANTOINETTE PERRIER, spinster of major age and with full use of her rights, of the city of Magog, district of St.Francis, defendant.\"The lot 1220 upon the official plan ami book of reference for the city of Magog; \u2014 lot of irregular form bounded to the north-east by lot 1219, to the south-west by lot 1221 and to the south-east by lot 1218, and to the north-west by the public street.The whole containing a superficies of 3959 feet, cnglish measure.\" To be solrl at the door of the parochial church of Ste-Margucritc-Maric rle Magog, WEDNESDAY the THIRTEENTH day of MAY, 1959.at TEN o'clock in the forenoon.JOSEPH LABRECQUE, Sheriff's Office, Sheriff.Sherbrooke, April 7th, 1959.50276-15-2-0 [Pirst insertion on the 11th of April, 1959] Index of the Quebec Official Gazette, No.15 Action for Separation as to Property: Bélisle vs Portier.1609 Orders in Council: 289-A \u2014 Construction, region of St-Hyacinthe.1609 289-C \u2014 Ornamental iron ami bronze, region of Montreal.1612 Notice to Intekested Parties: 1577 1642 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 11 avril 1959, Tome 91, N° 16 Avis divers: Association «les Chimistes professionnels du Québec (Membres).1013 Caisse Populaire Ste-Marguerite de Trois-Rivières (Nom changé).1015 Domaine Ix; Relais (Fondation).1015 (tarage Coopératif Beauceville (Fondation).1614 labrador Acceptance Corporation (Règlement).1615 l.a Caisse Populaire Marie Reine des Cœurs de Montréal (Fondation).1611 Im Corporation des Administrateurs Professionnels \u2014 The Corporation of Professionnal Administrators (Règlement) .101 I Syndicat d'Expansion Industrielle de Plessisville Inc.(Dût.de l'actif)____ 101 I The Insurance Institute of the Province of Quebec \u2014 L'Institut d'Assurance de la Province de Québec (Directeurs) 1013 The Priory School Inc.(Règlements).1015 The Royal Quebec Golf Club (Règlement).1613 Union Coopérative de Malartic (Fondation).1614 Victorian Order of Nurses, Lachine Branch \u2014 L'Ordre des Infirmières Victoria, Succursale Lachine (Règlements).1613 ('martes \u2014 Abandon de: Palomer Knitting Mills Ltd.1016 Syndicat d'Expansion Industrielle de Plessisville lue.1016 ( 'ompaonies dissoutes : A.Feldman Company.1616 Dorval Properties Ltd.1616 Drummond Café Inc.1617 Ilamelin & Hubbard Industries Corporation.1617 Hamilton Nursing Home Inc.1017 J.W.Martineau Ltée.1017 Kent Avenue Investment Corp.1618 Les Immeubles C.D.Jean Ltée.1018 Louis Roy & Fils, Limitée.1018 Montreal Industrial Land Company Limited.'.1018 Robert Limitée.1019 St.Philomènc Sand & Gravel (Thibert Pit) Ltd.1619 Swanson Mines Ltd.1619 Veritas Inc.1019 ( ïuratelle publique: Allen, succession Henry.1020 DÉPARTEMENTS- AVIS DES: Instruction publique: .1/utlicipaliié scolaire de: Louise ville.1620 Macamie.1021 Nicolet, ville.1620 Thetford-Mines.cité.1620 MlSCELLAN E< lis N ( >TI C ES : Association of Professional ( 'hcinists of Quebec (Members).1613 ( laisse Populaire Ste-Marguerite de Trois-Rivières (Naine changer!).1615 Domaine Le Relais (Foundation).1615 (îarage Coopératif Beauceville (Foundation).1614 Labrador Acceptance Corporation (By-Law).1615 La Caisse Populaire Marie Reine des Cœurs de Montréal (Foundation) .1614 Ixi Corporation des Administrateurs Professionnels \u2014 The Corporation of Professional Administrators (By-Law).1614 Syndicat d'Expansion Industrielle de ' Plessisville Inc.(Dist.of assets).1614 The Insurance Institute of the Province of Quebec L'Institut d'Assurance de la Province de Québec (Directors).1613 The Priorv School Inc.(By-Laws).1615 The Roval Quebec Golf Club (By-Law) *.1613 Union Coopérative de Malartic (Foundation).1614 Victorian Order of Nurses.Lachine Branch \u2014 L'Ordre des Infirmières Victoria, Succursale Lachine (By-Laws) .1613 Charters \u2014 Surrender of: Palomer Knitting Mills Ltd.1616 Syndicat d'Expansion Industrielle de Plessisville Inc.1616 ( !om p a n i es Dissolved : A.Feldman Company.1616 Dorval Properties Ltd.1616 Drummond Café Inc.1617 Ilamelin & Hubbard Industries Corporation.1617 Hamilton Nursing Home Inc.1617 .1.W.Martineau Ltée.1617 Kent Avenue Investment Corp.1618 Les Immeubles C.D.Jean Ltée.1618 Louis Roy & Fils, Limitée.1618 Montreal Industrial Land Company Limited.1618 Robert Limitée.1019 St.Philomènc Sand & (iravel(Thibert Pit) Ltd.1019 Swanson Mines Ltd.1619 Veritas Inc.f.1619 Public Curatorship: Allen, estate, Henry.1620 DEPARTMENTAL NOTICES: Education: School Municipality of: Louiseville.1620 Macamie.1621 Nicolet, town.1620 Thetford-Mines, city.1620 Mines: Révocation de Concessions minières.Mines: 1621 Cancellation of Mining Concessions.1621 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 1 1th, 1959, Vol.91, No.15 1643 Travail: Industrie ou métiers de: Barbier, coiffeur et coiffeuse, district de Saint-Francois (Modification).1621 Construction Hull et District (Modification) .1622 Voirie: Entretien des routes discontinué.Lettres patentes: Labour: Industry or Trades of: Barbering and hairdressing, district of St.Francis (Amendment).1621 Construction Hull et District (Amendment).1622 Roads: L622 Maintenance of roads discontinued, 1622 Letters Patent: Acron Investment Corp.1578 Adanac Aluminum Ltd.1579 Algonquin Chemicals Ltd.1579 A.L.M.Supply Inc.1579 Arrow Electronic Corp.1580 Association des Garçons de Table dc la Mauricie Inc.1580 A.& M.Restaurants Ltd.1580 Balmoral Products Ltd.1581 Bata Development Inc.1581 Belmont Démolition Inc.1581 Benoît Bernier Inc.1582 Bernard Lazarovitz Inc.1582 Bernier & Thibault, Ltée.1582 Blouin & Koury Incorporée.1583 Brand Building Corporation.1583 Cantrac Inc.1583 Cascade Realty and Development Company Limited.1584 Claire Investment Corp.1584 Consolidated Industrial Chemicals Corporation Limited.1584 Cowansvillc Art Center.1585 Dacoma Manufacl uring Co.Ltd.1585 Davmar Investment Corp.1585 D.& E.Investments Inc.1580 Delray Investments Limited.1586 Diploma Investments Inc.1586 Domaine St.Eustache Ltée.1587 Druna Investment Corp.1587 École de Tissage du Tapis d'Orient Inc.1587 E.IL Desmarais Incorporé.1588 Erta Realties Ltd.15S8 Fabi & Savard Ltée.1588 Gaspé Télévision Ltée.1589 Gatincau Recreation Association \u2014 Association Récréative Gatincau.1589 G.& B.Construction Ltd.1589 G.Beaudet et Compagnie Limitée.1590 Globe Transactions Inc.1590 G lol)ex Ltée \u2014 G loi >ex Ltd.1590 Gorlex Inc.1591 Growth Construct ion Co.1591 Henri Grenier Limitée.1591 Hôpital Général de Ville Emard General Hospital.1592 Hôpital Notre Dame de Grâce Hospital 1592 Howard-Ellen Holdings Ltd.1593 Ideal Inside Door Industries Ltd.1593 Karcm Holdings Corp.1593 Kores Mfg.Corporation.1591 Lacombe Transport Inc.1594 Lakesbore Caterers Ltd.1594 Lamart Development Co.Ltd.1595 La Plomberie André Inc.\u2014 André Plumbing & Heating Inc.1595 larkwood Investment Corporation.1595 Laval Roofing & Heating Co.Ltd.1590 Le Club de Golf dc Cap-Rouge Inc.\u2014 The Cap-Rouge Golf Club Inc.1596 Le Conseil du Bien-Être de Valleyfield \u2014 The Valleyfield Welfare Council.1590 Les Associés du Centre Audio-Visuel Inc.1597 Acron Investment Corp.1578 Adanac Aluminum Ltd.1579 Algonquin Chemicals Ltd.1579 A.L.M.Supply Inc.1579 Arrow Electronic Corp.1580 Association des (Jargons de Table de la Mauricie Inc.1580 A.& M.Restaurants Ltd.1580 Balmoral Products Ltd.1581 Bata Development Inc.1581 Belmont Démolition Inc.1581 Benoît Bernier Inc.1582 Bernard Lazarovitz Inc.1582 Bernier & Thibault, Ltée.1582 Blouin & Koury Incorporée.1583 Brand Building Corporation.1583 Cantrac Inc.1583 Cascade Realty and Development Company Limited.1584 Claire Investment Corp.1584 Consolidated Industrial'Chemicals Corporation Limited.1584 Cowansville Art Center.1585 Dacoma Manufacturing Co.Ltd.1585 Davmar Investment Corp.1585 D.& E.Investments Inc.1586 Delray Investments Limited.1586 Diploma Investments Inc.1586 Domaine St.Eustache Ltée.1587 Druna Investment Corp.1587 École de Tissage du Tapis d'Orient Inc.1587 E.H.Desmarais Incorporé.1588 Erta Reallies Ltd.1588 Fabi & Savard Ltée.1588 Gaspé Télévision Ltée.¦ .1589 Gatineau Recreation Association \u2014 Association Récréative Gatineau.1589 G.& B.Construction Ltd.1589 G.Beaudet et Compagnie Limitée.1590 Globe Transactions Inc.1590 Globex Ltée \u2014 Globex Ltd.1590 Gorlex Inc.1591 Growth Construction Co.1591 Henri Grenier Limitée.1591 Hôpital Général de Ville Emard General Hospital.1592 Hôpital Notre Dame de Grâce Hospital 1592 Howard-Ellen Holdings Ltd.1593 Ideal Inside Door Industries Ltd.1593 Karcm Holdings Corp.1593 Kores Mfg.Corporation.1594 Lacombe Transport Inc.1594 Lakesbore Caterers Ltd.1594 Lamart Development Co.Ltd.1595 La Plomberie André Inc.\u2014 André Plumbing & Heating Inc.1595 Larkwood Investment Corporation.1595 Laval Roofing & Heating Co.Ltd.1596 Le Club de Golf de Cap-Rouge Inc.\u2014 The Cap-Rouge Golf Club Inc.1596 Le Conseil du Bien-Êtrc de Valleyfield \u2014 The Valleyfield Welfare Council.1596 Les Associés du Centre Audio-Visuel Inc.1597 1644 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 avril 1959, Tome 91, N\" 16 Les Ateliers de Réparation et de Nettoyage de Tapis Inc.1597 Les Entreprises Asselin Inc.1598 Les Entreprises Greenland Inc.1598 Mademoiselle Shoppe Inc.1598 Maheu & Brisebois Automobile Incorporé.1599 Manufacturiers Moreau Manufacturing Inc.1599 Marcelle L.Inc.1599 Marcel Watier Inc.1600 Melling Co.Ltd.1000 Montreal Dog Obedience Training Club Inc.1600 Nor-Ficld Development Corp.1601 Norvil Construction Ltée \u2014 Norvil Construction Ltd.1601 O.Fontaine Construction Inc.1601 Omicron Realty Corp.1602 Orcan Realties Inc.1602 Palov Holdings Ltd.:.1602 Par love Realty Corp.1602 P-A-S- Associates Inc.1603 Raman Investment Corporation-.1603 Rami Construction Corp.1603 Renaissance Development Corporat ion.1604 S.B.Realties Ltd.1604 Shamross Realty Ltd.1604 Sherril Investments Ltd.1605 Société Organisée de Secours Incorporée \u2014 Society of Organized Safety Incorporated.1005 Spade (Quebec) Electrical Ltd.1606 Starling Corporation.1006 Studio Industries Ltd.1600 Sumac Land Corporation.1607 Tamarack Realties Corp.1607 The First Armenian Holy Apostolic Church.1608 Vallée Automobile Inc.1608 Wrightvillc Appliances Ltd.\u2014 Les Appareils Wrightvillc Ltée.100S Les Ateliers de Réparation et de Nettoyage dc Tapis Inc.1597 Les Entreprises Asselin Inc.1598 Les Entreprises Greenland Inc.1598 Mademoiselle Shoppe Inc.1598 Maheu & Brisebois Automobile Incorporé.1599 Manufacturiers Moreau Manufacturing Inc.1599 Marcelle L.Inc.1599 Marcel Watier Inc.1600 Melling Co.Ltd.1600 Montreal Dog Obedience Training Club Inc.1600 Nor-Ficld Development Corp.1601 Norvil Construction Ltée \u2014 Norvil Construction Ltd.1601 O.Fontaine Construction Inc.1601 Omicron Realty Corp.1602 Orcan Realties Inc.1602 Palov Holdings Ltd.1602 Parlove Realty Corp.1602 P-A-S- Associates Inc.1603 Raman Investment Corporation.1603 Rami Construction Corp.1603 Renaissance Development Corporation 1604 S.B.Realties Ltd.1604 Shamross Realty Ltd.1604 Sherril Investments Ltd.1605 Société Organisée de Secours Incorporée \u2014 Society of Organized Safety Incorporated.1605 Spade (Quebec) Electrical Ltd.1606 Starling Corporation.1606 Studio Industries Ltd.1606 Sumac Land Corporation.1607 Tamarack Realties Corp.1607 The First Armenian Holy Apostolic Church.1608 Vallée-Automobile Inc.1608 Wrightvillc Appliances Ltd.\u2014 Les Appareils Wrightvillc Ltée.1608 MINISTERE DES FINANCES: Assurances: North Pacific Insurance Company Limited.1624 Department of Finance: Insurance: North Pacific Insurance Company Limited.1624 Office des marchés agricoles du Québec: Avis (Tamendements de sanction de plan conjoint de mise en marché: lyJiitcric Mont Saint-Bruno, Producteurs-fournisseurs de lait.Rimouski-Matapédia, Producteurs de Rois de pulpe.Okdhe de Cour: Quintal vs Nichols.Sif.oes sociaux: A.& W.Restaurants Ltd.Beàconsfield Shopping Centre lue.Doreal Investments Ltd.Industrial Materials Supply Company Ltd.I m Cie d'Immeubles du Lac St-I^ouis Inc.La Ligue des Propriétaires d'AMaBaic Incorporée \u2014 AMaBaie Proprietors League Incorporated.I .a vallée Co.Ltd.Quebec Agriculture Marketing Board: Notice of amendments of sanction of joint marketing plan: laiterie Mont Saint-Bruno.Milk Pro- 1624 ducers-Supplicrs.1624 Rimouski-Matapédia.Pulpwood Pro- 1024 ducers.1024 Rule of Court: 1625 Quintal vs Nichols.1625 Head Offices: 1625 A.& VV.Restaurants Ltd.1625 1625 Reaconsfield Shopping Centre Inc.1625 1626 Doreal Investments Ltd.1620 Industrial Materials Supply Company 1020 Ltd.f.1620 La Cie d'Immeubles du Lac St-Ix>uis 1027 Inc.,.1627 AMaBaic Proprietors league Incorporated \u2014 \\ja Ligue des Propriétaires 1627 d'AMaBaie Incorporée.1627 1626 Lavallée Co.Ltd.1620 QUElilCC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 11th, 1959, Vol.91, No.15 1645 Les Entreprises du (Charme Inc.1627 Les Entreprises du Charme lue.1627 I^ongwood Acres Inc.>.1626 Longwood Acres Inc.1626 Unie Equipment Inc.1626 Unie Equipment Inc.1626 Soumissions: Tenders: Dorval, cité.1630 Dorval, city.1630 St-Anicet, comm.scolaire.1627 St-Anicet, school connu.1627 Ste-Foy.cité.1631 Ste-Foy, city.1631 Ste-Thérèse, cité.1629 Ste-Thérèse, city.1629 Vente d'effets non-réclamés: Sale of Unclaimed Goods: Canadian Pacific Express Company____ 1633 Canadian Pacific Express Company .1633 Ventes, Loi de faillite: Sales, Bankruptcy Act: Begin, Alhéric.1633 Begin, Albéric.1633 Begin, Albéric.1634 Begin, Albéric.1634 Taylor, Willie.1636 Taylor, Willie.1636 Vente par licitation: Sale by Licitation: Constant vs Constant.1637 Constant vs Constant.1637 Vente pour taxes: Sale for Taxes: Senneterre, ville.1637 Senneterre.town.1037 VENTES PAR SHÉRIFS: SHERIFFS' SALES: Abitibi: Abitibi: Loi de l'Impôt sur le revenu vs Bibeault.103X Income Tax Act vs Bibeault.1638 Beauharnois: Beauharnois: Poupard vs Pilon.1638 Poupard vs Pilon.1638 Bedford: Bedford: Windsor Credit Union Limited vs Windsor Credit Union Limited vs Poszek.1639 Poszek.1639 Chicoutimi: Chicoutimi Gauthier vs Tremblay.1639 Gauthier vs Tremblay.1639 Quebec Radio Television Enr.vs Bon- Quebec Radio Television Enr.vs Bou- dreault.1640 dreault.1040 Hull: Hull: Interprovincial Rldg., Cr.Ltd.vs Interprovincial Bldg., Cr., Ltd., vs Dugré.1640 Dugré.1640 Roberval: Roberval: Côté, Boivin & Cie Inc.vs Grenier et al.1640 Côté, Roivin & Cie Inc.vs Grenier et al.1640 Saint-François: St.Francis: La ( 'ité de Magog vs Perrier.1641 La ( 'ité de Magog vs Perrier.1641 Quebec: '-Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014Printed by Rédemptj imprimeur de la Reine.Queen's Printer. "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.