Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 août 1959, samedi 22 (no 34)
[" Tomb 91, N° 34 3307 Vol.91, No.34 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Qukbkc, samedi 22 août 1959 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1959.Québec, le 20 juin 1959.LTmprimeur de la Reine, 50831-25-1 l-o RÊDEMPTI PARADIS.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1' Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, August 22nd, 1959 RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1959.Quebec, June 20th.1959.REDEMPTI PARADIS, 50831-25-1 l-o Queen's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hcreinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 3308 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 août 1959, Tome 91, N° SA préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rrmhourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, k vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remue doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de k Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéresses sont priés d'en avertir ITmpruneur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces: Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement : 87 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni ele notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502\u2014l-52-o Lettres patentes (P.G.12997-59) Albany Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la \\a)\\ des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mai 1959, constituant en corporation: Claude Behind, Jean F.Laureys, tous deux avocats, et Francis .lanes Undcrdown, ingénieur de ventes, tous de Montréal, pour les objets suivants : Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Albany Investment will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., arc strictly payable in aelvance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.'Hie Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is ent it led to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents ]>er agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: S7 per year.X.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion ; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS.Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th.1940.41502 \u2014 l-52-o Letters patent (A.G.12997-59) Albany Investment Corporation Xoticc is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of May, 1959, incorporating: Claude Belaud.Jean P.Laureys, both advocates, and Franc-is Janes Underdown, sales engineer, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Albany Invest- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 22nd, 1959, Vol.91, No.SI 3309 Corporation\", avec on capital total de $40,000, divise en 2,000 actions privilégiées de S10 chacune 2.000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.,!>.(;.12929-59) Alexander Vida Co.* Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze mai 1059, constituant en corporation: Alexander Vida, marchand, de Montréal, Irène Gauron, de St-Pierre, et Marielle Pilotte, de Montreal, toutes deux secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Exercer le commerce de tanneurs, corroyeurs, teinturiers, fabricants de ceintures et vendeurs de toutes sortes de pelleteries, cuirs bruts, peaux de jeunes animaux, peaux, cuirs et succédanés produits et sous-produits d'iccux, sous le nom de de \"Alexander Vida Co.\".avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE.ment Corporation\", with a total capital stock of $40,000.divided into 2,000 common shares of $10 each and 2.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of Mav.1959.I».FRENETTE, 51261-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12029-59) Alexander Vida Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of May, 1959, incorporating: Alexander Vida, merchant, of Montreal.Irène Gauron, of St.Pierre, and Marielle Pilotte.of Montreal, both secretaries, spinsters* filles majeures, for the following purposes: To carry on the business of tanners, curriers, dyers, belting manufacturers and manufacturers of and dealers in all kinds of pelts, bides, kips, skins, leathers and substitutes and products and by-products thereof, under the name of \"Alexander Vida Co.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 400 shares of SI00 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of Mav.1959.P.FRENETTE, 51261 -o Acting Deputy Attorney General.(P.O.12812-59) Anada Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze mai 1959, constituant en corporation: Harold S.Freeman, Daniel Morris, tous deux de Montréal, et John Jacob Wasserman.de West-niount.tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Anada Investment Corp.\", avec un capital total de $1.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 cl lacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1959.I.Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE.(P.G.13048-59) Auto Imports Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1959, constituant en corporation: Raymond Lette, avocat, de Hampstead, Hélène Gélinas, avocat, et Rolande Rech, secrétaire, toutes deux filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, vendre, importer, exporter et négocier et faire le commerce d'automobiles, camions, pièces d'automobiles, aéronefs, moteurs d'avions, bateaux à moteurs, radios, réfrigérateurs, bicyclettes, motocyclettes et accessoires, sous le nom (A.G.12812-59) Anada Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May, 1959, incorporating: Harold S.Freeman, Daniel Morris, both of Montreal, and John Jacob Wasserman, of Westmount, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Anada Investment Corp.\", with a total capital stock of $1,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May, 1959.P.FRENETTE, 51261-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13048-59) Auto Imports Ltd.Notice is hereby given that under Part.I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1959, incorporating: Raymond Lette, lawyer, of Hampstead, Hélène Gélinas, lawyer, and Rolande Rech, secretary, both spinsters of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To buy, sell, import, export and trade and deal in motor cars, motor trucks, motor parts, aircraft, aircraft motors, motor boats, radios, refrigerators, bicycles, motorcycles and accessories, under the name of \"Auto Imports Ltd.\", 3310 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quelle, 22 août J959, Tome 91, N° SL tic \"Auto Imports Ltd.\", avec un capital-actions divisé en 300 actions sans valeur nominale ou au pair et 150 actions privilégiées de $100 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $3,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, tlistrict judiciaire de Montréal.Daté du hiire.au du Procureur général, le vingt et un mai 1059.L'Assistant procureur général suppléant, 51201 P.FRENETTE.(P.G.13072-59) Autoroute Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ixii des compagnies de Quelle, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux mai 1959, constituant en corporation: John Maria Cerini, Victor St-Onge, tous deux de Montréal, et Robert Learmont Jamieson, de Pointe Glaire, tous avocats, pour les objets suivants : Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Autoroute Enterprises Ltd.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions de $10 chacune.Le siège sociable la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE.with a capital stock divided into 300 shares having no nominal or par value and 150 preferred shares of $100 each, and the amount with which the company will commence its operationa will be $3,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-first dav of Mav, 1959.P.FRENETTE, 51261 -o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13072-59) Autoroute Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of May, 1959, incorporating: John Maria Cerini, Victor St-Onge, both of Montreal, and Robert Learmont Jamieson, of Pointe ( ïjaire, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a land, development and construction company, under the name of \"Autoroute Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of May, 1959.P.FRENETTE, 51261-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12789-59) Aztec Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ixii des compagnies de Québec, il a été accordé pur le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze mai 1959, constituant en corporation : Seymour Maclilovitch, Morris Chaikclson, avocats, Yolande Dcslauriers, secrétaire, fille majeure, tous trois de Montréal, et Gisèle LeBlanc, secrétaire, épouse séparée de biens dudit Marcel LeBlanc, de St-Bruno, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et construction, sous le nom de \"Aztec Realties Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 9,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1959.L'Assistantprocureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE.(A.G.12789-59) Aztec Realties Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1959, incorporating: Seymour Maclilovitch, Morris Chaikclson, advocates, Yolande Dcslauriers, secretary, fille majeure, all three of Montreal, and Gisèle LeBlanc, secretary, wife separate as to property of Marcel Leblanc, of St.Bruno, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Aztec Realties Inc.\", with a total capita] stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of SI each and 9.000 preferred shares of $1 each.The head office o» the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1959.P.FRENETTE, 51261-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12596-59) Bcrtdale Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec des lettres patentes, en date du premier mai 1959, constituant en corporation: Seymour Maclilovitch, Morris Chaikelson, tous deux avocats, de Montréal, et Gisèle LeBlanc, secrétaire, épouse séparée de biens de Marcel LeBlanc, de St-Bruno, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le (A.G.12596-59) Bcrtdalc Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of May, 1959, incorporating: Seymour Maclilovitch, Morris Chaikelson, both advocates, of Montreal, and Gisèle LeBlanc, secretary, wife separate as to property of Marcel LeBlanc, of St.Bruno, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 22nd, 1969, Vol.91, No.34 33H nom ec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of April, 1959, incorporating : Manuel Shactcr.of Dorval, Leo Rosentzveig and Staidey Taviss, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of wholesale and retail florists, nurserymen, market gardeners, fruit growers and seedsmen in all its branches, under the name of \"Harry's Flower Den Inc.\".with a total capital stock of $10.000, divided into 1,000 common shares of $1 each, 5,000 class \"A\" preferred shares of $1 each and 4,000 class \"B\" preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51261-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12008-59) Heron Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of April, 1959, incorporating: David Goodman, of the town of Hampstead, Melvin Rothman, of Westmount, Godfroy Marin, of Pointe Claire, all three advocates, and Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, improvement, development and construction company, under the name of \"Heron Investment Corp.\",'with a total capital stock of $10,000, divided into 200 common shares of $10 each and 800 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 5126l-o Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE. 3320 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 août 1969.Tome 91.N° SA (P.G.12598-59) Jandale Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a é'té accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier mai 1959, constituant en corporation: Seymour Maclilovitch, Morris Chaikelson, avocats, de Montréal, et Gisèle LeBlanc, secrétaire, épouse séparée de biens de Marcel LeBlanc, de St-Bruno.pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Jandale Development Corp.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 5.000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 9720 rue Jeanne Mance, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51201 P.FRENETTE.(A.G.12598-59) Jandale Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor f the Province of Quebec, bearing date the first day of May.1959, incorporating: Seymour Machlovitch Morris Chaikelson, advocates, of Montreal, and Gisèle LeBlanc,\" secretary, wife separate as to property of Marcel LeBlanc, of St.Bruno, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under the name of \"Jandale Development Corp.\", with u total capital stock of $5.000, divided into 5.000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at 9720 Jeanne Mance Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney (icncral, this first day of May.1959.P.FRENETTE, 51261-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12953-59) Jardins Mont Plaisant Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze mai 1959.constituant en corporation: Louis Orcnstein, avocat, Alan Golden, gérant, tous deux d'Outremont, Jason Ruby, avocat, Danièle Blanchard, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, et Huguette St-Marseille, secrétaire, fille majeure, de l'Ile Perrot, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et construction, sous le nom de \"Jardins Mont Plaisant Inc.\", avec un capital total de $10,000.divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et 90 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE, (A.G.12953-59) Jardins Mont Plaisant Inc.Notice is hereby given that under Pari 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of May, 1959, incorporating: Louis Orenstein, advocate.Alan Golden, manager, both of Outre-mont, Jason Ruby, advocate, Danièle Blanchard, secretary, fille majeure, both of Montreal, and Huguette St-Marseille, secretary, fille majeure, of Ile Perrot, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Jardins Mont Plaisant Inc.\", with a total capital stock of $10.000.divided into 100 coin-mon shares of $10 each and 90 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of May, 1959.P.FRENETTE, 51261-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12995-59) Jcdby Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mai 1959, constituant en corporation: Claude Behind, Jean F.Laureys, tous deux de Montréal, et Harry H.Harris, de Pointe-aux-Trembles, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Jcdby Corporation\", avec un capital total de $40,000.divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mai 1959.(A.G.12995-59) Jedby Corporation Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies'.Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of I he Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of May, 1959, incorporating: Claude Belaud, Jean F.Laureys, both of Montreal, and Harry H.Harris, of Pointe-aux-Trembles, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Jedby Corporation\", with a total capital stock of $40.000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of May, 1959.P.FRENETTE, 51261-0 Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec.August 22nd, 1959, Vol.91.No.34 3321 (P.G.12334-59) Jerry Shears Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt avril 1959, constituant en corporation: Irving L.Adessky, Melvin Salmon, et Moscs Moscovitch, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses spécialités, le commerce de courtiers et agents d'assurances, sous le nom de \"Jerry Shears Co.Ltd.\", avec un capital total de 120,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 1.500 actions privilégiées de SI0 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt avril 1959.I.'Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE.(P.G.12350-59) Kirkor Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la lx>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un avril 1959, constituant en corporation: Irving L.Adessky, Moscs Moscovitch, tous deux de Montréal, et Melvin Salmon, de Côte St-Luc, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Kirkor Investment Corp.\", avec un capital total de $10.000.divisé en 200 actions ordinaires de $5 chacune et 900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un avril 1959.L'A>sistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE.(P.G.12861-59) Kraon Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date \u2022lu douze mai 1959, constituant en corporation: Avrain Harold Garmaise, Sydney Weisbord, comptables agréés, et Jeanine-L.Fobert, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Kraon Holdings Inc.\", avec un capital total de $9,000, divisé en 9,000 actions de $1 chacune.Ix- siège social de la compagnie sera à 1905 rue nipper, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1059.L Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE.ff.G.12745-59) Life-Time Home Inspection Service Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a «e accordé par le Lieutenant-gouverneur de la (A.G.12334-59) Jerry Shears Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of April.1959, incorporating: Irving L.Adessky, Melvin Salmon and Moses Moscovitch, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on in all its branches the business of insurance brokers and agents, under the name of \"Jerry Shears Co.Ltd.\".with a total capital stock of $20.000.divided into 500 common shares of $10 each and 1.500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney (icncral, this twentieth dav of April.1959.P.FRENETTE, 51261-0 Acting Deputy Attorney (icncral.(A.G.12356-59) Kirkor Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of April, 1959, incorporating: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch, both of Montreal, and Melvin Salmon, of Côte St.Luc, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a land, development ami construction company, under the name of \"Kirkor Investment Corp.\".with a total capital stock of $10,000.divided into 200 common shares of $5 each and 900 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first dav of April.1959.P.FRENETTE, 51261-o Acting Deputy Attorney (icncral.(A.G.12861-59) Kraon Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1959, incorporating: Avram Harold Garmaise, Sydney Weisbord, chartered accountants, ami Jeanine-L.Fobert, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Kraon Holdings Inc.\", with a total capital stock of $9.000.divided into 9,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at 1905 Tupper Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of Mav, 1959.P.FRENETTE, 51261-Q Acting Deputy Attorney General.(A.G.12745-59) Life-Time Home Inspection Service Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 3322 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 août 19Ô9, Tome 91, .V° SA province de Québec des lettres patentes, en date du huit mai.1959, constituant en corporation: Irwin S.Hrodie, Theodore H.Polisuk, avocats, Sonyn Schncycr et Julie Surcn, secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «pli consiste à inspecter et faire rapport sur la condition de propriétés immobilières et constructions, sous le nom de \"Life-Time Home Inspection Service Inc.\", avec un capital total de $10,000.divisé en 10,000 actions de $1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à 6555 chemin Côte des Neiges, chambre 225, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le huit mai 1959.L'Assistant-priK'iireur général suppléant, 51261 P.PRÉNETTE.(P.C.12471-59) Linsol Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-(piatre avril 1959, constituant en corporation: Samuel David Rudeiiko, conseil en loi «le la Reine.Clarence Reuben Gross, Rollin Gallay, tous trois avocats, et Sarah Miller, sténographe, fille majeure, tous «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «lans les spécialités suivantes «le marchandises; machinerie neuve et usagée, outillage, rebuts ferreux et non-ferreux, automobiles et accessoires «l'icelles, marchandises ferreuses et non-ferreuses, neuves et usagées, fournitures et outillage neufs et usagés pour la marine et la plomberie, outillage et fourniture motorisés pour le chemin «le fer, meubles, produits en caoutchouc, plastique, Incite, verre, bakélite, produits chimiques ainsi que tous objets produits ou fabriqués en totalité ou en partie de métal; d'aliments, préparations alimentaires, pâtisserie, et produits chimiques, produits laitiers, produits «le la viande, épiceries et articles de commerce comestibles et habits, vêtements de toutes sortes, sous le nom de \"Linsol Enterprises Inc.\", avec un capital total de $10.000, divisé en 1.000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le vingt-«piatre avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE.(P.G.12726-59) Lyndon Development Corp.Avis est donné «pi'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en «late «lu six mai 1959, constituant en corporation : John L.Liberman.Alfred N.Segall, Max Teitlebaum, avocats, et Marilyn Denny, secrétaire, fille majeure, tous «le Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce d'une compagnie «le construction générale et d'immeubles et celui d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Lyndon Development Corp.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $10 chacune et 900 ac- Province of Quebec, bearing dale the eighth day of May, 1959, incorporating: Irwin S.Brodie Theodore H.Polisuk.advocates, Sonya Schneyer and Julie Suren, secretaries, filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of inspecting and reporting upon the condition of immoveable property and constructions, under the name of \"Life-Time Home Inspection Service Inc.\" with a total capital stock t>f $10.000, divided into 10,000 shares of $1 each.The head office of the company will de at 6555 Côte des Neiges Road, Room 225.Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eighth day of May.1959.P.FRENETTE, 51261-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12471-59) Linsol Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of April, 1959, incorporating: Samuel David Rudcnko, Queen's Counsel.Clarence Reuben Gross.Rollin Gallay.all three advocates, and Sarah Miller, stenographer, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business in the following lines of merchandise; new and old machinery, equip, ment, ferrous and non-ferrous scrap, automobiles and automobile supplies, new and used ferons, and non-ferrous goods, new and used marine and plumbing supplies and equipment, automotive and railroad equipment and supplies, furniture, rubber, plastic.Incite, glass and bakélite products, chemicals as well as all por-ducts produced or manufactured in whole or in part from metal; in food-stuffs, food preparations, confectionery, ami chemical product-, milk produits, meat products, groceries and articles of commerce suitable for concumption and in clothing and wearing apparel of all kind-, under the name of \"Linsol Enterprises Inc.\", with a total capital stoek of $10.000.divided into 1.000 shares of $10 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of April.1959.P.FRENETTE, 51261-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12726-59) Lyndon Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patenl have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of Mav 1959, incorporating: John L.Liberman, Alfred'N.Segall, Max Teitelbaum, advocates, and Marilyn Denny, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To operate as a general construction and real estate company and to carry on the business of an investment company, under the name of \"Lyndon Development Corp.\", with a total capital stock of $10,000.divided into 100 common shares of a par value of $10 each and 900 preferred I QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 22nd, 1959, Vol.91, No.3A 3323 lions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 265 ouest, me Craig, chambre 250, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE.shares of a par value of $10 each.The bead office of the company will l>e at 265 Craig Street West, Room 250, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of Mav, 1959.P.FRENETTE, 51261-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12463-59) Majestic Quebec Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1959.constituant en corporation: Camil Noël, conseil en loi de la Reine, Jacques Alleyn, Claude Rioux, tous trois avocats, Mlle Agathe Ferron, secrétaire, et Paul Mcctcau, échevin, tous de Québec, pour les objets suivants: Construire, installer, entretenir, réparer et exploiter des \"pipe-lines\" de tout genre et description, sous le nom de \"Majestic Quebec Inc.\", avec un capital total de $50.000.divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $50 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Ix- siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE.(A.G.12463-59) Majestic Quel>oo Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of April, 1959, incorporating: Camil Noël, Queen's Counsel, Jacques Alleyn, Claude Rioux, all three attorneys, Miss Agathe Ferron, secretary, ami Paul Mecteau, alderman, all of Quebec, for the following purposes: To construct, lay, maintain, repair and operate pipe lines of every type and description, under the name of \"Majestic Quebec Inc.\", with a total capital stock of $50.000.divided into 400 common shares of a par value of $50 each and 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth dav of April.1959.P.FRENETTE, 51261-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12001-59) Mar no! Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1959, constituant en corporation: Gregory Charlap, Max Slapack et Arthur Shul-inan.tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le conunerce général de courtiers en immeubles et agents à commission, sous le nom de \"Marnel Enterprises Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 50 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1181 ouest, rue Ste-Catherine, 2e étage, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51201 P.FRENETTE.(P.G.12345-59) Maurice Developments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quélwc, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1959, constituant en corporation: Yehuda Elbcrg, administrateur, Daniel Kingstone, avocat, et Katherine Ingledew, sténographe, célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'im-jneubles et développements, sous le nom de \"Maurice Developments Ltd.\", avec un capital (A.G.12901-59) Marnel Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May, 1959, incorporating: Gregory Charlap, Max Slapack and Arthur Shulman, all advocates, of Montreal, for the following purposes : To carry on business generally as real estate brokers and commission agents, under the name of \"Marnel Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 500 common shares of $10 each and 50 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 1181 St.Catherine Street.West 2nd floor, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of May, 1959.P.FRENETTE, 51261-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12345-59) Maurice Developments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of April, 1959, incorporating: Yehuda Elberg.executive, Daniel Kingstone, advocate, and Katherine Ingledew, stenographer, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and development company, under the name of \"Maurice Developments Ltd.\", with a total capital 3324 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 août 1959, Titme 91.N° SA total de $40,000, divisé en 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51201 P.FRENETTE.(P.G.12719-59) Maushel Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date «lu huit mai 1969, constituant «-n corporation: Melvin Rothman, avocat, «le Westmount, (io«l-froy Marin, avocat, «le Pointe Claire, et Sylvia Vincberg, secrétaire, fille majeure, «le Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Maushel Development Corp.\", avec un capital total de $40,000.«livisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social île la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau «lu Procureur géimral.le huit mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51201 P.FRENETTE.stock of $40,000, i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec «les lettres patentes, en date du huit mai 1959, constituant en corporation: Luc Geoffroy, de Chambby, Robert Duhide, de Dorion, et Robert-Y.Lanthier, de Ste-Rose, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une c«>mpagnie d'immeubles, sous le nom de \"Ste.Sophie Land Holdings Ltd.\", avec un capital-actions divisé en 100 actions sans valeur nominale ou au pair, l< montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $500.Le siège social de la compagnie sera 60 rue De Caumont, Bouchcrville, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1959.par value of $50 each and 300 preferred shares of a par value of $50 each.The bead office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth dav of March, 1959.P.FRENETTE, 51261-o Acting Deputy Attorney (icncral.(A.G.12823-59) Ruskin Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1959, incorporating: Manuel Shatter, of Dorval.Stanley Taviss and William Levitt, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To invest in and hold land and real estate, under the name of'\"Ruskin Investment Corp.\"-.with a total capital stock of 81.000, divided into 1.0(H) common shares of 81 each.The bead office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office «>f the Attorney General, this twelfth day of May.1059.P.FRENETTE, 51261 -o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12653-59) St-Elzéar Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the first day of May 1959, incorporating: Abraham Sinister, advocate.Nathaniel Liebman, notary, ami Carl Rosen, law student, all «>f Montreal.f«>r the following purposes: To carry on the business of general contractors, under the name of \"St-Elzéar Construction Inc.\".with a total capital stock of 840.000, divided into 500 common shares of $10 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The bead office of the company will l>e at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May.1959.P.FRENETTE, 51261-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12724-59) Ste.Sophie Land Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May 1959, incorporating: Luc Geoffroy, of Chambly, Robert Dulude, of Dorion, ami Robert-Y.Lanthier.of Ste.Rose, all lawyers, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Ste.Sophie Land Holdings Ltd.\", with a capital stock divided into 100 shares having no nominal or par value, and the amount with which the company will commence its operations will be $500.The head office of the company will be at 60 Dc Caumont Street.Bouchcrville, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of Mav, 1959.P.FRENETTE, 51261-o Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant.51261 t p.FRENETTE. 3330 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 août 1969, Tome 91, N° SJ, (P.G.12732-59) Sambcrn Investment Corp.Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mai 1959, constituant en corporation: Bernard Garmaise, de ville Mont-Royal, David SokolofF et Sydney SokololF, d'Outremont, tous marchands, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Sambcrn Investment Corp.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six mai 1959.L'Assistant-procureur général supplé'ant, 51261 P.FRENETTE.(P.G.12595-59) Senate Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier mai 1959, constituant en corporat ion : Seymour Maclilovitch, Morris Chaikelson, tous deux avocats, de Montréal, et Gisèle LeBlanc, secrétaire, épouse séparée de biens dudit Marcel LeBlanc, de St-Bruno, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, développement, et construction, sous le nom de \"Senate Development Corp.\", avec un capital total de 85,000.divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 9720 rue Jeanne Mance, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 51201 P.FRENETTE.(A.G.12732-59) Sambcrn Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of May, 1959, incorporating: Bernard Garmaise, of the town of Mount Royal, David Sokololf and Sydney SokolofT, of Outrcmont, all merchants, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Sambern Investment Corp.\".with a total capital stock of 810.000, divided into 400 common shares of 810 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May.1959.P.FRENETTE, 51261-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12595-59) Senate Development Corp.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of May, 1959, incorporating: Seymour Maclilovitch, Morris Chaikelson, both advocates, of Montreal, and Gisèle LeBlanc, secretary, wife separate as to property of Marcel LeBlanc, of St.Bruno, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under the name of \"Senate Development Corp.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 5,000 common shares of $1 each.Thc-head office of the company will be at 9720 Jeanne Mance Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1959.P.FRENETTE, 51261-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12635-59) Sharand Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1959, constituant en corporation: John L.Liberman, Alfred N.Segall, Max Teitelbaum, tous trois avocats, et Marilyn Denny, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Sharand Construction Ltd.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 8581 avenue Outremont, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1959.(A.G.12635-59) Sharand Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1959, incorporating: John L.Liberman.Alfred N.Segall, Max Teitelbaum, all three advocates, and Marilyn Denny, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors and builders, under the name of \"Sharand Construction Ltd.\", with a total capital stock of $20.000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and 1.000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 8581 Outrcmont Avenue.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1959.P.FRENETPE, 51261-o Acting Deputy Attorney (icncral.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETPE. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 22nd, 1959, Vol.91, No.SA 3331 (P.G.12593-59) Shclborne Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date dû premier mai 1959, constituant en corporation: Seymour Maohlovitch, Morris Chaikelson, tous deux avocats, de Montréal, et Gisèle LeBlanc, secrétaire, épouse séparée de biens dudit Marcel Leblanc, de St-Bruno, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Shclborne Development Corp.\", avec un capital total de $5,000.divisé en 5,000 actions ordinaires de Si chacune.Le siège social de la compagnie sera à 9720 rue Jeanne Mance, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51201 P.FRENETTE.(P.G.12809-59) Shoreview Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze mai 1959, constituant en corporation: David Zilbert, Mayer Nisker et David Nisker, tous marchands, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et les activités dé constructeurs et entrepreneurs généraux et celui d'agents d'immeubles dans toutes ses spécialités, sous le nom de \"Shoreview Development Corp.\", avec un capital total de Si0.000, divisé en 600 actions ordinaires de S10 chacune et 500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51201 P.FRENETTE.(A.G.12593-59) SI ie 1 bon h- Development Corp.Notice is hereby given tlmt under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of May, 1959, incorporating: Seymour Maclilovitch, Morris Chaikelson, both advocates, of Montreal, and Gisèle LeBlanc, secretary, wife separate as to property of Marcel Leblanc, of St.Bruno, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under the name of \"Shclborne Development Corp.\", with a total capital stock of 85,000.divided into 5,000 common shares of 81 each.The head office of the company will be at 9720 Jeanne Mance Street.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney (icncral, this first dav of Mav.1959.P.FRENETTE, 51261-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12809-59) Shoreview Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies* Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May, 1059.incorporating: David Zilbert, Mayer Niske;' and David Nisker, all merchants, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and activities of general builders and contractors and the business of real estate agents in all its branches, under the name of \"Shoreview Development Corp.\", with a total capital stock of 810.000, divided into 500 common shares of 810 each and 500 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney (icncral, this eleventh dav of Mav.1959.P.FRENETTE, 51261-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12747-59) Shouedy Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des letties patentes, en date du huit mai 1959, constituant en corporation: Melvin Rotliman, de Westmount, Godfroy Marin, de Pointe Claire, tous deux avocats, et Sylvia Vineherg, secrétaire, fille majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Shouedy Development Corp.\", avec un capital total de 840.000, divisé en 2.000 actions ordinaires de 810 chacune et 2.000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le '\"'it mai 1959.(A.G.12747-59) Shouedy Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May.1959, incorporating: Melvin Roth-man, of Westmount.Godfroy Marin, of Pointe (Taire, both advocates, and Sylvia Vinebcrg, secretary, fille majeure, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under the name of \"Shouedy Development Corp.\", with a total capital stock of 840.000, divided into 2.000 common shares of 810 each and 2.000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May, 1959.P.FRENETTE.51261-0 Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant.01261 P.FRENETTE. 3332 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 août 19Ô9, Tome 91, N° SA (P.G.11901-59) Soissons Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du vingt-six mars 1959, constituant en corporation: Sema Black, secrétaire, fille majeure, «le Montréal.Charles Brownstcin, de ville Côte St-Luc, et Irving L.Adessky.«le Montréal, tous deux avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie «le placements et construction, sous le nom de \"Soissons Enterprises Inc.\", avec un capital total «le 820,-000, divisé en 1,500 actions ordinaires «le 810 chacune et 500 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt-six mars 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51201 P.FRENETTE.(P.G.I2S13-59) Spruce Investment Corp.Avis est flonné «m'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en «late du onze mai 1959, constituant en corporation: Harold S.Freeman.Daniel Morris, tous deux de Montréal, et John Jacob Wasserman, de Westmount, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom «le \"Spruce Investment Corp.\", avec un capital total «le 81.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE.(A.G.11901-59) Soissons Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-sixth day of March.1959, incorporating: Sema Black, secretary, fille majeure, of Montreal Charles Brownstein, «>f the town of Côte St.Luc, and Irving L.Adessky, of Montreal, both advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment and general construction company, under the name of \"Soissons Enterprises Inc.\".with a total capital stock «>f 820.000.divided into 1.500 common shares of 810 each and 500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office f the Attorney General, this twenty-sixth day «>f March, 1959.P.FRENETTE.51201-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12813-59) Spruce Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May, 1959, incorporating: Harold S.Freeman, Daniel Morris, both of Montreal, and John Jacob Wasserman, of Westmount, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Spruce Investment Corp.\", with a total capital stock of -SI ,000.divided into 1,000 common shares of the par value of 81 each.The hcail office «>f the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May, 1959.P.FRENETTE, 51261-«> Acting Deputy Attorney General.(P.G.12068-59) Statemen Land Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie tie la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec tics lettres patentes, en «late du huit mai 1959, constituant en corporation: Luc Geoffroy, de Cbambly, Robert Dulude, de Dorion, et Robert-Y.Lanthier, de Ste-Rose, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie «le placements, sous le nom «le \"Statemen Land Holdings Ltd.\", avec un capital-actions divisé en 100 actions sans valeur nominale ou au pair, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de 8500.Le siège social tie la compagnie sera à 403 est, rue Sherbrooke, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1959.(A.G.12068-59) Statemen land Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quepec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May, 1959, incorporating: Luc Geoffroy, of Chambly, Robert Dulude, of Dorion, and Robert-Y.Lanthier, of Ste.Rose, all lawyers, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Statemen Land Holdings Ltd.\", with a capital stock divided into 100 shares having no nominal or par value, and the amount with which the company will commence its operations will be 8500.The head office of the company will he at -10.1 Sherbrooke, Street East, Montreal, judicial (listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May.1959.P.FRENETTE, 51261-o Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, Augu.it 22nd, 1959.Vol.91, No.Si 3333 (P.G.12800-59) Steel Storage Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la If $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day «>f Mav, 1959.P.FRENETTE, 51261 -o Acting Deputy Attorney General.(A.G.1272S-59) Sussex Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters paient have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the sixth day of May, 1959.incorporating: John L.Liberman, Alfred N.Segall.Max Teitelbaum.advocates, and Marilyn Denny, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To operate as a general construction and real estate company and to carry on the business of an investment company, under the name of \"Sussex Development Corp.\", with a total capital stock of $10,000.divided into 100 common shares «)f a par value of $10 each «uni 900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 265 Craig Sticet West.Suite 350.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of Mav.1959.P.FRENETTE, 51261-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12727-59) Sutton Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day «>f May 1959.incorporating: John L.Liberman, Alfred N.Segall.Max Teitelbaum, advocates, and Marilyn Denny, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To operate as a general construction ami real estate company and to carry on the business of an investment company, under the name of \"Sutton Development Corp.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of a par value of $10 each and 900 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at 265 Craig Street West.Suite 350.Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of Mav.1959.P.FRENETTE.50261-o Acting Deputy Attorney General.L Assistant-procureur général suppléant, 512°1 P.FRENETTE. 3334 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 août 1959, Ttrme 91, N° Si (P.G.12793-59) Tarkor Leather Goods Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze mai 1959, constituant en corporation: Nathan Robins.Michael N.Robins, fabricants, et Gregory Charlap, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fabricants et marchands de bourses, sacs, sacoches, ensembles de toilette pour dames, accessoires pour dames, nouveautés, articles de fantaisie, cuir, tissus et autres matières premières et articles semblables, sous le nom de \"Tarkor leather Goods Co.'\", avec un capital total de 8200,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de 81 chacune et 19.500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1405 rue Maisonneuve, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51201 P.FRENETTE.(A.G.12793-59) Tarkor Leather Goods Co.Notice; is hereby given that under Part lof the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day\u201e of May, 1959, incorporating: Nathan Robins.Michael N.Robins, manufacturers, and Gregory Charlap, advocate, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers in ladies' purses, ladies' bags, briefcases, toilet sets, ladies' accessories, novelties, novelty goods, leather, fabrics and other raw materials and similar articles, under tin name of \"Tarkor Leather Goods Co.\", with a total capital stock of 8200.000.divided into .\">.000 common shares of 81 each and 19.500 preferred shares of 810 each.The head office of the company will lie at 1405 Maisonneuve Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1959.P.FRENETTE, 51261-0 Acting Deputy Attorney (\"encrai.(P.G.12538-59) The Mill Coffee Shops Inc.Avis est donné (pi'en vertu de la première partie de la Ixii des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente avril 1959, constituant en corporation: Lionel iA'inay, agent d'affaires, de St-Michel, Richard Dorais, avocat.Hernade Charette, Huguette Lessard et Pierrette Grenier, sténographes, filles majeures, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de \"The Mill Coffee Shops Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 4.000 actions ordinaires de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51261 P.FRENETTE.(A.G.12538-59) The Mill Coffee Shops Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec- Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of April, 1959, incorporating: Lionel Ixinay, business agent, of St.Michel, Richard Dorais, lawyer, Remade Charette, Huguette Lessard and Pierrette Grenier, stenographers, spinsters, all four of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, under the name of \"The Mill Coffee Shops Inc.\".with a total capital stock of 840,000.divided into 4.000 common shares of $10 each.The head office of the company will Le'at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney (icncral, this thirtieth day of April.1959.P.FRENETTE.51261-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12550-59) The Royal Embassy Hotel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ixn des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept avril 1959, constituant en corporation: Samuel Chait, avocat, John Hamilton, secrétaire, tous deux de Montréal, et Harry L.Aronovitch, avocat, de la ville Côte St-Luc.pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôtel, motel, taverne, auberge et/ou restaurants ou toute combinaison d'iceux, sous le nom de \"The Royal Embassy Hotel Inc.\".avec un capital-actions divisé en 100,000 actions sans valeur nominale ou au pair, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses activités sera de $500,000.Le siège social de la compagnie sera à 3407 rue Peel.Montréal, district judiciaire de Montréal.(A.G.12550-59) The Royal Embassy Hotel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of April.1959, incorporating: Samuel ('liait, advocate, John Hamilton, secretary, both of Montreal, and Harry L.Aronovitch, advocate, of the town of Côte St.Luc.for the following purposes: To carry on the business of hotel, motel, tavern, public house and/or restaurant or any combination thereof, under the name of \"'I he Royal Embassy Hotel Inc.\".with a capital stock divided into 100,000 shares wit bout nominal or par value, and the amount with which the company will commence is operations will be $500.000.The head office of the company will be at 3407 Pell Street, Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quctwc, August 22nd, 1969, Vol.91, No.8Jt 3335 Daté our les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Tierra Development Corp.\", avec un capital to'.al de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 3500 rue Ridgewood, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1059.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261 P.FRENETTE.(P.G.12620-69) Treetown Developments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mai 1959, constituant en corporation: Yehuda Elberg, administrateur, Katherine Ingle-dew, sténographe, fille majeure, et Daniel King-stone, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et d'amélioration, sous le nom de \"Tree-town Developments Ltd.\", avec un capital total f William Gaffney, and duly authorized by him, both of Montreal, and Ann Druzin, secretary, spinster of full age of majority, of Longueuil.for the following purposes: To carry f the Secretary :.f the Province, July sixth, 1959.RAYMOND DOUVIL1 E, 51266 Assistant Secretary of the Province.L'ASSOCIATION PATRONALE DES BARBIERS ET COIFFEURS DU COMTÉ DE LOTBINIÈRE (I/>i «les syndicats professionnels) lj& fonnation d'une société, sous le nom de \"L'Association Patronale des Barbiers et ('oiffeurs du Comté «h- Lotbinière\", p«>ur l'étude, la défense et le développement «les intérêts économiques, sociaux et moraux «le ses membres, a été aut«>ri-sée par le Secrétaire «le la province le vingt-trois juillet 1959.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Sainte-Croix, comté «le Ixdbinière.lie Sous-secrétaire «le la province, 51 278m.RAYMOND DOUVILLE.L'ASSOCIATION PATRONALE Dix BARBIERS ET COIFFEURS l>( COMTÉ DE LOTBINIÈRE (Professional Syndicates' Act ) The formation of an association under tin- name of \"L'Association Patronale «les Barbiers et Coiffeurs du comté «le Lotbinière\", for the study, «lefence ami promotion of the economic, social ami moral interests of its members, lia» been authorized by the Provincial Secretary i the twenty-third day of July 1959.The principal place of business of the said professional symlicate is at Sainte Cr«>i\\.county «>f Lotbinière.RAYMOND DOUVILLE, 51278 Assistant Secretary of the Province.SYNDICAT DES BRIQl'ETEURS-PLÂTRIERS DES CANTONS DE L'EST (I,oi «les syndicats professionnels) Avis est donné «pie l'honorable Secrétaire «le la province a, le vingt-trois juillet 1959, autorisé le changement «le nom du syndicat professionnel \"Le Symlicat «les Brhpietiers et PlAtriers de la Cité «le Sherbrooke\", dont la fonnation a été autorisée le 16 mai 1930, avec siège social à Sherbrooke, «listrict judiciaire de Saint-Franf the Professional Syndicates' Act (R.S.Q.1911.chapter 162).(Jiven at the office of the Provincial Sei tar}', the fifth day of August.1959.RAYMOND DOUVILLE, 51279 Assistant Secretary of the Province.LES CHARPENTIERS DE LEMOYNE Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original «le la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Les Charpentiers de LeMoyne\", en date du 2 juillet 1959, dont le siège social est situé à Candiac, «listrict judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives «lu Secrétariat «le la province.Donné au bureau du Secrétariat «le la province, le sept août 1959.Le Sous-secrétaire de la province, 51281-0 RAYMOND DOUVLLLE.ISRAEL LOAN SYNDICATE Avis est, par les présentes, donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Israel Loan Syn- LES CHARPENTIERS DE LEMOYNE Notice is hereby given that the How urable the Provincial Secretary has duly received the thir«l copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Les Charpentiers de LeMoynè\", under date of ¦'¦ d.y 2, 1959, whereof the head office is at Candiac, judicial district of Montreal, ami that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.(iiven at the office of the Provincial Sec < tary, this seventh day of August, 1959.RAYMOND DOUV1LLI 51281 Assistant Secretary of the Province.ISRAEL LOAN SYNDICATE Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate 'Israel QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 22nd, 1959, Vol 91, No.34 3343 dii.ii.'.en date du 3 décembre 1958, dont le siège social est à Montréal, district judiciaire de Montréal, et que ledit document a été déposé dam les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce onzième jour d'août 1959.Ia?Sous-secrétaire de la province, 51297 RAYMOND DOUVILLE.(P.O.10723-59) LAURENTIAN GAS COMPANY COMPAGNIE DE GAZ LAUR ENTIENN E Règle me ut II Changeant le nombre de directeurs de cinq à sept.idniinistrateurs \u2014 Nombre et.qualification l'u conseil d'administration de sept (7) administrateurs sera élu chaque année et chaque administrateur sera le détenteur d'au moins une action du capital-actions de la compagnie.-le, soussigné, secrétaire de \"Laurentian Gus Company \u2014 Compagnie de Gaz Lauren tienne\", certifie par ies présentes que le règlement précité a été édicté par les administrateurs de la compagnie à une assemblée régulière tenue le 4 mars 19 »9, et a été approuvé et sanctionné par tous les actionnaires de la compagnie à une assemblée spéciale générale tenue subséquemment le môme jour.A l'assemblée des administrateurs tous les administrateurs étaient présents.A l'assemblée spéciale générale des actionnaires tous les actionnaires étaient présents.Ix> Secrétaire, 51290-o ANDRÉ PÏCHÉ.OTBOUGAMAU VENTURE LIMITED (No Personal Liability) Sommaire du règlement numéro S Que l'actif de la compagnie soit divisé au pro rate entre les actionnaires de la compagnie.Certifié sommaire véritable, 17 août 1959.Le Secrétaire, 51298 JOHN G.FORD.Chartes \u2014 Abandon de Loan Syndicate\", under date December 3rd, 1958, whereof the bead office is at Montreal, Judicial District of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this eleventh dav of August.1959.RAYMOND DOUVILLE, 51297-o Assistant Secretary of the Province.(A.G.10723-59) LAURENTIAN GAS COMPANY COMPAGNIE DE GAZ LAl'RENTIENNE By-lau II (\"banging the number of directors from five to seven.Directors \u2014 Number and qualification A board of seven (7) directors shall be elected annually, and each director shall be the owner of at least one share of the capital stock of the company.I.the undersigned Secretary of \"Laurentian Gas Company - Compagnie de Gaz Laurent ien-iie\".hereby certify that the above by-law was enacted by the directors of the company at a regular meeting held on March 4th.1959, ami was unanimously approved and sanctioned by all the shareholders of the company at a special general meeting hold later on the same day.At the meeting of directors, all the directors were present.At the meeting of shareholders, all the shareholders were present.ANDRÉ PICHÉ, 51290-o Secretary.CHTBOUGAMAU VENTURE LIMITED (No Personal Liability) Summary of By-law number S That the assets of the company be divided ratably among the shareholders of the company.Certified true summary.August 17th, 1959.JOHN G.FORD, 51298-0 Secretary.Charters \u2014 Surrender of GOHTER ENTERPRISES LTD.LES ENTREPRISES GOHTER LTÊE »>.is est, par les présentes, donné que la compagnie \"(Johier Enterprises Ltd.\u2014 Les Entreprises (Joiner Ltée\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la cité de Montréal, dei uidera au Procureur général de la province di Québec la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Ix)i des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 6e jour d'août 1959.Le Seen'taire, (Signé) J.EMILE DUCHARME.'\u2022' Procureurs & Solliciteurs, Keating & Drody, 152 est, rue Notre-Dame, Montréal.51268 (JOHIER ENTERPRISES LTD.LES ENTREPRISES (JOHIER LTÉE Notice is hereby given that \"Gobier Enterprises Ltd.\u2014 Les Entreprises (Johier Ltée\", constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 6th dav of August, 1959.(sgd) J.ÉMILE DUCHARME, Secretary.Keating & Drody.Barristers & Solicitors.152 Notre-Dame Street East, Montreal.51268-o 3344 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 août 1959, Tome 91, N° SA CANADIAN ELASTIC WEAVING CO.Avis est par les présentes donné (pie \"Canadian Elastic Weaving Co.\", s'adressera au Procureur général et au Ministre des Affaires municipales de l'Insdustrie et du Commerce pour permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 26 juin 1959.Le Procureur de Canadian Elastic Weaving Co., PHILIP S.GARONCE.1449 rue St.Alexandre.Montréal.51267-0 CANADIAN ELASTIC WEAVING CO.Notice is hereby given that \"Canadian Elastic Weaving Co.\", will make application to the Attorney General and to the Minister of Municipal Affairs, Trade and Commerce, for leave to surrender its charter.Montreal.June 26th, 1959.PHILIP S.GARONCE, Attorney lui Canadian Elastic Weaving Co.1 149 St.Alexander Street, Montreal.'> 12(17-0 UNITED LIVESTOCK SALES (QUEBEC) LIMITED Avis est, par les présentes, donné que \"United Livestock Sides (Quebec) Limited\", une corporation constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, district de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Iyoi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 12e jour d'août 1959.Ixî Secrétaire, 51269 RALPH GRANT McKEE.UNITED LIVESTOCK SALES (QUEBEC) LIMITED.Notice is hereby given that \"United Li < stock Sales (Quebec) Limited\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its bead office in the city of Montreal, «listrict of Montreal, will apply to the Attorney (icncral of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec ( 'ompanics' Act.Dated at Montreal, this 12th dav of August, 1959.RALPH GRANT McKEE, 51269-0 .Secretary.ST-PAULIN LUMBER INC.Avis est par les présentes donné (pie la compagnie \"St-Paulin Lumber Inc.\", ayant son siège social à Montréal, demandera au Procureur général la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 17 août 1959.lx> Procureur de St-Paulin Lumber Inc., 51299-0 EERNAND GUERTIN.ST-PAULIN LUMBER INC.Notice is hereby given that \"St-Paulin Lumber Inc.\", having its bead office in the city and district of Montreal, will apply to the Attorney General for authorization for surrender its charter.Montreal, this 17th dav of August, 1959.FERNAND GUERTIN, Attorney for 51299-o St.Paulin Lumber Inc.Compagnies dissoutes (P.G.14894-58) ACTON VALE SILK MILLS LIMITED Avis est donné (pi'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec.1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Acton Vale Silk Mills Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 22 mai 1933.Avis est de plus donné qu'à compter du trente juillet 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général.le trois août 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261-o P.FRENETTE.Companies Dissolved (A.G.14894-58) ACTON VALE SILK MILLS LIMITED Notice is hereby given that under Paît I of the Quebec Companies' Act.section 26, chapter 276.R.S.Q.1941.and subject, to the liability enacted by section 27 of the said Act.the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Acton Vale Silk Mills Limited\", incorporated under said Part I of the Quebec ('ompanics' Act, by letters patent dated May 22, 1933.Notice is also given that from and after the thirtieth day of July 1959, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of August.1959.P.FRENETTE, 51261 Acting Deputy Attorney General.(P.G.18115-53) HANSON BROS.INVESTMENTS, LIMITED Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur (A.G.18115-53) HANSON BROS.INVESTMENTS, LIMITED Notice is hereby given that under Part I of the Quebec (\"ompanics' Act, section 26.chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the sur- QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, Quebec, August 22nd, 1959, Vol 91, No.3A 3345 général d'accepter l'abandon «le la charte «le la compagnie \"Hanson Bros.Investments, Limited*', constituée en corporation en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, par lettres patentes en «late du 6 février 1928.Avis est «le plus donné qu'à compter du trente juillet 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le trois août 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261-0 P.FRENETTE.(P.G.10042-59) HUDSON INVESTMENT LTD.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec.1941, chapitre 276, article 26.et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi.il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte «le la compagnie \"Hudson Investment Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en «late «lu 8 mai 1954.Avis est de plus donné qu'à compter du 30 juillet 1959.ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le trois août 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261-0 P.FRENETTE.render of the charter of the company \"Hanson Bros.Investments, Limited\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated February 6.1928.Notice is also given that from and after the thirtieth day of July, 1959.the said company has been dissolved.Date«l at the office of the Attorney (icncral, this third day of August.1959.P.FRENETTE, 51261 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10042-59) HUDSON INVESTMENT LTD.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charier of the company \"Hudson Investment Ltd.\".incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, bv letters patent dated May 8, 1954.Notice is also given that from and after the thirtieth day of July 1959, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of August, 1959.P.FRENETTE, 51261 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14067-57) LAKE ST.JOSEPH REALTY COMPANY LTD.COMPAGNIE D'IMMEUBLE DU LAC ST.JOSEPH LTÉE v is est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec.Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée p n l'article 27 «le hulite loi, il a plu au Procureur ral d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Lake St.Joseph Realty Company L Compagnie d'Immeuble du Lac St.pli Ltée\", constituée en corporation en vertu i ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en «late du 18 \u2022 h ;olne 1934.* Avis est de plus donné qu'à compter du trente juillet 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le trois août 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261-0 P.FRENETTE.(A.G.14067-57) LAKE ST.JOSEPH REALTY COMPANY LTD.COMPAGNIE D'IMMEUBLE DU LAC ST.JOSEPH LTÉE Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Lake St.Joseph Realty Company Ltd.\u2014 Compagnie d'Immeuble du Lac St.Joseph Ltée\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent «lated October IS, 1934.Notice is also given that from and after the thirtieth day of July 1959, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney (icncral.this third day of August 1959.P.FRENETTE, 51261 Acting Deputy Attorney (icncral.(P.G.11903-58) LA SOCIÉTÉ MONTMORENCY INC.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, Statuts refondus «le Québec, 1941.chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de la«lite loi, il a plu au Procureur général «l'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"La Société Montmorency Inc.\", constituée en corporation en vertu «le ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 21 décembre 1956.(A.G.11903-58) LA SOCIÉTÉ MONTMORENCY INC.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"La Société Montmorency Inc.\", incorporated under the said Part I of the Quebec ('ompanics' Act.by letters patent «lated December 21, 1956. 3346 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 août'1959, Tome 91, N° 3A Avis est «le plus donné qu'à .compter du trente et un juillet 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le trois août 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 51261-0 P.FRENETTE.Notiee is also given that from ami after July thirty-first 1959, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney Genera], this third day of August, 1959.P.FRENETTE, 51261 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11003-59) OUELLET & ARCAND INC.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité «lécrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général «l'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Ouellct & Arcand Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la lx>i des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 11 décembre 1954.Avis est de plus donné qu'à compter du trente et un juillet 1959.ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le trois août 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261-0 P.FRENETTE.(A.G.11003-59) OUELLET & ARCAND INC.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26.chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Ouellet & Arcband Inc.\", incorporated under l'art I of the Quebec Companies' Act.by letter.- patent dated December 11.1954.Notice is also given that from and after July thirty-first 1959, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this thin! day of August, 1959.P.FRENETTE, 51261 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12140-59) M EDA.INC.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refontlus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Mcda, Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 20 avril 1956.Avis est de plus donné qu'à compter du trente juillet 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le trois août 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261-o P.FRENETTE.(A.G.12140-59) MEDA, INC.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, section 2b.chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act.the Attorney (icncral has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Meda, Inc.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated April 20.1956.Notice is also given that from and aftei July thirtieth, 1959, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this third day of August.1959.P.FRENETTE, 51261 Acting Deputy Attorney General.(P.G.10432-59) MAISON IRÈNE INC.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon «le la charte de la compagnie \"Maison Irène Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies «le Québec, par lettres patentes en date du 29 février 1956.Avis est de plus donné qu'à compter du trente juillet 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau «lu Procureur général, le trois août 1959.(A.G.10432-59) MAISON IRÈNE INC.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, section 26.chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Maison Irène Inc.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, by letters pateid dated February 29, 1956.Notice is also given that from and after July thirtieth, 1959, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this third day of August.1959.P.FRENETTE, 51261 Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant, 51261-o P.FRENETTE. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, August 22nd, 1959, Vol.91, No.31, 3347 Département de l'Instruction publique N° .MS-57.MUNICIPALITÉ SCOLAIRE DE ROXRORO Demande est faite de détacher de la municipal), scolaire de Côte St-Rémi de Ste-Genevièvc Np l.dans le comté «le Jacques-Cartier, le lot 291 du cadastre officiel de la municipalité de Dollard des Ormeaux, pour l'annexer, pour les con'ill niables catholiques seulement, à la municipalité scolaire catholique de Roxboro, dans le même comté.Québec, le 11 août 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 51JiS-33-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 722-59.MUNICIPALITÉ DE STE-MONIQUE-DES-SAULES Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Ste-Monique-des-Saules, dans le comté de Québec, en celui de \"Les Saules\", menu- comté.Qnébee, le 6 août 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 51249-33-2-0 0.J.DÉSAULNIERS.N° 1-J2-49.MUNICIPALITÉ SCOLAIRE DE ST-CÉSAIRE Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de la paroisse de St-Césaire, dans le comté de Rouville, à la municipalité scolaire du village de St-Césaire.menu- comté et de changer le nom de cette dernière en celui de la municipalité scolaire de St-( i -aire, dans le comté de Rouville.< ec, le 12 août 1959.11 surintendant de l'Instruction publique.51273-34-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.V 207-59, M UNICIPALITÉ SCOLAIRE DE ST-HERM ÉN ÉGILDE mande est faite de changer le nom de la jnui ipalité scolaire de St-Herménégilde, dans le c \u2022 té de Stanstead en celui de la municipalité se ire de Belval, dans le comté de Stanstead.Ou bec, le 12 août 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 51271-34-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 355-59.MUNICIPALITÉ SCOLAIRE DE LOWER-LITCHFIELD Demande est faite d'annexer, pour les contribuables protestants seulement, le territoire actuel f Ascot j municipality of city of Sherbrooke) registration division of Sherbrooke.Notice is hereby given that lots 15-1 25 and 15-F-26 are cancelled in virtue of Arth' Î174A «>f the Civil Code.Quelle.August 9.1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch.AVILA BÉDARD, 51262-o Deputy Mini iter.Official cadastre of the parish of Pointe-Claire (municipality of town of Pointe-Claire) registration division of Montreal.Notice is hereby given that lot 113-88 has been cancelle«l in virtue of Article 2174A of the Civil (\"ode.Quelle, August 5.1959.AVILA BÉDARD, 51262-o Deputy Minister.Official cadastre «>f St-Antoine Ward (municipality of city of Montreal) registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 1491-A.1492, 1492-A, 1492-B and part of lots 1490 and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 22nd, 1959, Vol.91, No.SA 3349 1490 et 1491-B sont annulés et le lot 1916 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 7 août 1959.Ix* Département des Terres et Forêts, Sendee du Cadastre, Le Sous-ministre, 51262-0 AVILA BÉDARD.1491-B \"are cancelled and lot 1916 has heen added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, August 7.1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 51262-o Deputy M inister.Cadastre officiel revisé du village de Princeville (municipalité de village de Princeville) division d'enregistrement «l'Arthabaska.Wis est par la présente donné que les lots 10-3, 27-2 et une partie des lots 2-A-16-2, 2-20, 10-4, 10-5, 26-2 sont annulés et le lot 286 esl ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 9 août 1959.Ia' Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 51262-0 AVILA BÉDARD.Officiai cadastre revise of village of Princeville (municipality of village of Princeville) registration division of Arthabaska.Notice is hereby given that lots 2-19, 10-3, 27-2 and a part of lots 2-A-16-2, 2-20, 10-4, 10-5, 26-2 are cancelled and lot 286 has been added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.* Quebec, August 9.1959.Department of Lamds and Forests, Cadastral Branch.AVILA BÉDARD, 51262-o Deputy M inister.Cadastre officiel de la paroisse «le Charlesbourg (municipalité «le ville «le Charlesbourg) division d'enregistrement «le Québec.Avis est par la présente donné que le lot 689-139 est annulé en vertu de l'article 2174A du ( 'ode civil.Quéla-c, le 10 août 1959.Le Département «les Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, .51262-0 AVILA BÉDARD.Officiai cadastre of the parish of Charlesbourg (municipality of town «>f Charlesbourg) registration division of Quel>ec.Notice is hereby given that lot 689-139 has been cancelled in virtue of Article 1274A of the Civil Code.Quebec.August 10, 1959.Department of Lands ami Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 51262-o Deputy M inister.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION l.'houorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes conformément aux dispositions de la loi «le la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux employés de garages des cités de Sherbrooke et Thetford Mines, rendue obligatoire par le décret N° 828 du 16 juillet 1953 et amendements, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret, dans sa teneur modifiée: 1° Ia?paragraphe \"j\" «le l'article I sera remplacé par le suivant: \"i) Garage: Le mot \"garage\" désigne tout endroit où les véhicules-moteurs sont réparés, transformés, démolis ou remisés.Sont considérés comme garages et par conséquent assujettis au décret, tous les établissements où se fait, exclusivement ou en partie, la réparation des accessoires ou pièces nécessaires à la conduite ou au fonctionnement «l'un véhicule-moteur, que ces accessoires ou pièces soient séparés du véhicule-automobile ou non.La présente définition ne comprend pas les établissements industriels exploitant de façon accessoire un garage, atelier de mécanique, station de service, en autant qu'ils limitent leurs services à leurs propres véhicules ou accessoires t't t|u ils n'accomplissent aucun travail pour la clientèle publique.\" Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette.Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), that contracting parties to the collective labour agreement relating to the garage employees of the cities of Sherbrooke and Thetford Mines, rendered obligatory by the decree No.828 of July 16, 1953 and amendments, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the said decree, as amended: 1.Paragraph \"j\" of article I will l>e replaced by the following: \"j) Garage: The word \"garage\" means any place where motor vehicles are repaired, transformed, demolished or stored.All establishments engaged, exclusively or partly, in the repair of parts or accessories necessary for the driving or operation of a motor-vehicle, whether or not the parts or accessories be part of the motor vehicles, shall be considered as garages and, consequently, governed by the decree.The present definition does not include industrial establishments operating as an accessory a garage, a machine shop or service station inasmuch as their services be exclusively limited to their own vehicles or accessories and be not performed for the public.\" 3350 (1AZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 août 1959, Tome 91.N° 34 2° L'article II sera remplacé par le suivant: 2.Article II will be replaced by the following; \"II.Juridiction: a) Juridiction professionnelle: \"II.Jurisdiction: a) Professional jurisdiction: Sont assujettis aux dispositions du présent décret.Those governed by the provisions of the present tous les employeurs, les employeurs profession- decree shall be the employers, professional nels, les artisans et les salariés (excepté le chef employers, artisans and employees (with the ou gérant du département des pièces et accès- exception of the chief or manager of the parts soires et le chef et gérant de service) des garages, and accessories department and service manager) «les débits d'essence, des stations de service, ter- of garages, gasoline stations, service stations rains de stationnement, terrains de démolition, parking grounds, scrapping yards, machine' ateliers de mécanique, magasins de pièces et des shops, parts stores and establishments engaged établissements où l'on fait la vente de parties in the sale of automobile parts or accessories ou accessoires d'automobiles, situés dans la juri- situated within the territorial jurisdiction of the diction territoriale du décret.decree.b) Juridiction territoriale: Le décret s'appli- b) Territorial jurisdiction: The decree applies que aux cités de Sherbrooke et Magog et à toutes to the cities of Sherbrooke and Magog and all les municipalités situées en entier ou en partie municipalities completely or partly i -11 *-< 1 dans un rayon de dix (10) milles de leurs limites, within a radius of ten (10) miles from their et à la cité de Thctford-Mines et dans un rayon limits, and to the city of Thetford-Mines and a de cinq (5) milles de sés*limites.\" radius of five (5) miles from its limits.\" 3° L'article III sera remplacé par le suivant: 3.Article III will be « placed by the loi wing: \"III.Salaires minima: Pour les fins de tariff- \"III.Minimum wages: For the purposes of cation des salaires, la juridiction territoriale determining wages, the territorial jurisdiction est divisée en trois (3) zones comme suit: is divided into three (3) zones as follows: Zone I: La cité de Sherbrooke et un rayon Zone I: The city of Sherbrooke and a radius de dix (10) milles de ses limites.of ten (10) miles from its limits.Zone II: La cité de Thetford-Mines et un Zone II: The city.of Thetford-Mines and a rayon de cinq (5) milles de ses limites.radius of five (ô) miles from its limits.Zone III: La cité de Magog et un rayon de Zone III: The city of Magog and a radius of dix (10) milles de ses limites.ten (10) miles from its limits.Les taux de salaires minima sont les suivants The following shall be the minimum wage pour chacune des catégories ci-après mentionnées: rates for the categories hereafter mentioned : Zones I II III a) Apprentis \u2014 Apprentices: L'heure\u2014 Per hour De 16 à 20 ans \u2014 From 16 te» 20 years: Première année \u2014 First year.80.85 $0.80 $0 70 Deuxième année - Second year.0.95 0.90 0.80 Troisième année \u2014 Third year.1 00 0.95 0.85 De 20 ans et plus -20 years of age or older: Première année \u2014- First year.1.00 0.95 0.85 Deuxième année \u2014 Second year.1.10 1.05 0.95 Troisième année \u2014- Third year.1.20 1.15 1.05 b) Compagnon \u2014 Journeyman: Deuxième classe \u2014 Second class.1.40 1.35 : 25 Première classe \u2014 First class.\u2022.1.55 1.50 1.40 c) Homme de service \u2014 Service man: Apprenti de 16 à 20 ans - Apprentice of 16 to 20 years of age: Première année \u2014 First year.0.65 0.60 0.50 Deuxième année \u2014 Second year.0.75 0.70 0.60 Troisième année \u2014 Tliird year.0.80 0.75 0.65 Apprenti de 20 ans et plus \u2014 Apprentice of 20 years of age or older: Première année \u2014 First year.\u2022 0.80 0.75 0 65 Deuxième année \u2014 Second year.0.90 0.85 0.75 Troisième année \u2014 Third year.-.1 00 0.95 0 85 Deuxième classe \u2014 Second class.1.05 1.00 0.90 Première classe \u2014 - First class.1.15 1.10 1 00 d) Concierge \u2014 Janitor and night watchman.0.85 0.80 0.70 e) Préposé aux pièces de rechange \u2014 Spare parts employee: Par semaine \u2014 Per ireek Préposé, 4ième classe \u2014 Clerk, 4th class.$35.25 832.80 *2\".i»0 Préposé, 3ième classe \u2014 Clerk, 3rd class.40.25 37.80 32 90 Préposé, 2ième classe \u2014 < 'lerk, 2nd class.48.25 45.80 40.90 Préposé, 1ère classe \u2014 Clerk, 1st class.58.25 55.80 50.90 A compter du 15 juillet 1960, les taux ci-haut mentionnés seront majorés de $0.05 l'heure./) Nonobstant les dispositions de l'article Vil, un salarié de quelque catégorie que ce soit qui travaille comme homme de service et gardien, du samedi midi au lundi matin (7.00 a.m.) ou un jour chômé, peut être rémunéré au taux horaire minimum de $0.95.Cependant, si au cours de cette période, il doit exécuter du travail appartenant à son propre métier, il doit alors être rémunéré au taux déterminé pour son métier pendant tout le temps ainsi consacré.\" From July 15, 19(50, the above rates shall be increased by $0.05 per hour./) Notwithstanding the provisions of article VII, employees of any one category who work as service men and watchmen, from 12.00 (noon) Saturday to 7.00 a.m.Monday or on any day kept as a holiday, shall be paid a minimum of ninety-five ($0.95) cents per hour, but if, during that period, they have to work in their own tratio, they shall be paid accordingly for the number of hours so worked.\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quelle, August 22nd, 1959, Vol.91, No.3Jf 3351 !J Lc premier alinéa du paragraphe \"a\" de |-u ùcle V sera remplacé par le suivant: \"V.fl) Jours chômés: Zones I et II: Les jours chômés sont les suivants: les dimanches, le Premier de l'An, l'Epiphanie, le Vendredi-Saint, l'Ascension, la Toussaint, l'Immaculée Concep-tion, la Noël, la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), |(.1er juillet (Confédération) et la fête du Travail.\" ,'\u2022>\u2022-.\u2022¦.5° L'article XIX sera remplace par le sui- \"XIX.Durée du décret: Le présent décret est valable à compter de sa publication dans la Gazette officielle de Québec et demeure en vigueur jusqu'au 15 juillet 1961.L'une ou l'autre des parties désirant modifier le décret doit en avertir l'autre partie par lettre recommandée au moins quatre (4) mois avant la date de son expiration.A défaut de ce faire, ledit décret sera automatiquement renouvelé pom une période supplémentaire d'un an.\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoires cis dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de.Quél>ec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés .pourront désirer formuler.Iao, Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 22 août 1959.51280-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), cpie les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la construction dans la région de Sorel lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes au décret numéro 602 du 9 juin 1954, et amendements relatif à l'industrie de la construction dans la région de Sorel.1° B.N.Rancourt Ltée sera ajouté aux parties contractantes de première part.2° L'item suivant sera ajouté dans l'échelle de salaires apparaissant à 1'artiele III.avant les mots \"Ferblantier-couvreur\": Zones I II ''Kleetricien (homme de ligne).Si .65 $1.55\" La publication du présent avis ne rend pas ol icatoires les dispositions qui y sont contenues.i un arrêté ministériel peut rendre obligatoires 1 - dispositions, avec ou sans amendement.I .rrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.1 Mirant les trente jours à compter, de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer b under.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, i^uébec, le 22 août 1959.51280-o 4.The first sub-paragraph of paragraph \"a\" of article V will be replaced by the following: \"V.o) Holidays: Zones I and III: The following days shall be kept as holidays: Sundays, New Year's Day.Epiphany, Good Friday, Ascension Day, All Saints' Day, Immaculate Conception, Christmas Day, St.John the Baptist Day (June 24), Confederation Day (July 1st) and Labour Day.\" 5.Article XIX will be replaced by the following : \"XIX.Duration of the decree: The present decree comes into force from the date of its publication in the Quebec Official Gazette and remains in force until July 15, 1961.Either contracting party wishing to amend the decree shall notify the other party by registered letter at least four (4) months l>efore the date of its publication.Failing such notice, the said decree shall be ante matically renewed for one year.\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order in Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties mav wish to setforth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec.August 22, 1959.51280-n NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments)# that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the construction industry in the region of Sorel.have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the decree No.602 of June 9th, 1954, and amendments, relating to the construction industry in the region of Sorel.1.B.N.* Rancourt Ltée will be added to the contracting parties of the first part.2.The following item will be added in the wage scale appearing in article III, before the words \"Tinsmith-roofer\" : Zones I 11 \"Electrician (lineman).$1.65 $1.55\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order in Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to setforth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 22, 1959.51280-o 3352 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 août 1969, Tome 91, N° SI Département de la Voirie Department of Roads AVIS Le ministère de la Voirie eessera à l'avenir d'entretenir les sections de routes ci-après désignées, parce qu'elles sont devenues inutiles pour la circulation: Dans la municipalité de St-JLéonard, comté de Nicolet : Route No 13 \u2014 Trois-Rivières-Drummond-ville-Acton Vale-Granby-( lowansville-Abercorn : Une section de 1030 pieds, à l'ouest de la nouvelle route, sur ou vis-à-vis les lots Nos 19, 20 et 21.Dans la municipalité de la paroisse de Ste-Agatbe, comté de Terrebonne: Chemin Stc-Agatbc-Ste-Lucie : Une section de 730 pieds, au sud-ouest du nouveau chemin, sur ou vis-à-vis les lots Nos P-12 et P-13, rang VI.Québec, le 14 août 1959.Le Ministre de la Voirie, 51294-o ANTONIO TALROT.NOTICE The Department of Roads will cease hen after to maintain the sections of roads hereinafter designated because they have become useless to traffic: In the municipality of St-Léonard, county of Nicolet: Route No.13 \u2014 Trois-Rivières-Drummond-vi 1 lc-Acton Vale-(irani>y-Cowansvi 1 le-A1 lercorn ¦ A section of 1030 feet, west of the new route on or facing lots Nos.19, 20 and 21.In the municipality of the parish of Ste-Agathe county of Terrebonne: Stc-Agathe-Sfee-Lucie Road : A section of 730 feet, on the southwest of the new road, on or facing lots Nos.P-12 and P-13, range VI.Quebec, August 14, 1959.ANTONIO TALBOT.51294 Minister of Roads.Examen des Agronomes Agronomists Examination La Corporation des Agronomes de la province de Québec Aspirants à l'étude de l'agronomie \u2014 Candidates to the study of Agriculture Tableau contenant les noms, prénoms, âge et domicile des aspirants à l'étude de l'agronomie, ainsi que le nom des institutions où ils ont étudié.Table containing the names, surnames, age and residence of candidates to the study of Agriculture and also the name of the institutions where they have studied.Noms et prénoms Names and surnames Domicile Residence Age Institutions Alarie, Hélène.Armstrong, Ross.Bastien, Denis.Bazinet, Pierre.Bédard, Réjean.Bélair, Yvon.Belzile, André.Belzile, Reginald.Bertrand, Gilles.Bourgeois, Jean.Bussières, Charles-Henri.Charland, Yvan.Choquette, Kenneth.Cou tu, Mario.Dousett, William-Arthur.Garceau, Jean.Grimard, Bernard.Jacob, Guy.Kennedy, Elaine.Kingsley, Jacques.Labelle, Gilles____ Lavigne, Pierre.Légaré, Gaston.Létourneau, Real.Mageau, Alain.McMorine, Kenneth.Mondou, Marcel.Morin, Rénald.Ostiguy, Florent.Ste-Annc-dcla-Pocatière, comté de Kamouraska.41 G, 3rd Avenue, Ottawa, Ont.1600, rue Champigny, Ville St- Laurent, Montréal 9.84, boulevard Magenta, Farnham, P.Q., Ste-Justine, comté de Dorchester.St-Joseph du Lac, comté des Deux-Montagnes.Amqui, comté de Matapédia.Amqui, comté de Matapédia.St-Canut, comté des Deux-Montagnes.St-Albert, Ontario.4, rue Principale, comté de Verchè-res.Ferme expérimentale, Lennox-ville, P.Q.9221, rue Bcrri, Montréal 11.Ste-Elisabeth, comté de Jolictte.R.R.2, Val d'Or, Québec.Pointe du Lac, Trois-Rivières.1052, rue Visitation, Montréal 24.782, 20ième rue, Québec 3.3417 Lacombe Avenue, Montréal 26 96, rue Noël, Ottawa, Ont.54, rue Donck, Laval-des-Rapides, Montréal 40.1429, rue Davidson, Montréal.213, i'Ormière, Loretteville, Québec.Clarenceville, comté de Missisquoi.4483, rue de Lorimicr, Montréal 34.Kingsbury, Richmond county, Que.Mnrieville.comté de Rouville.St-Anselme, comté de Dorchester.Marieville, comté de Rouville.18 17 19 18 19 26 19 16 23 19 23 22 18 19 17 21 20 17 18 18 23 20 17 sl7 28 18 19 18 École Supérieure d'Agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière.Glebe Collegiate Institute.Université de Montréal.Écolo Supérieur St-Romuald de Farnham.Ecole Supérieure d'Agricultuie fie Ste-Anne-de-la-Pocatière.Séminaire de Ste-Thérèse.Institut Agricole d'Oka.École Supérieure d'Agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière.Collège de Lachute.Grand Séminaire d'Ottawa.Collège de Longueuil.Séminaire St-Charles-Borromée.École Scientifique Lafond.École Secondaire St-Viateur.Percival County High School 'le Val d'Or.Académie de La Salle.École Supérieure Le Plateau.Collège Bourget de Rigaud.St.Augustine's High School.Académie de La Salle.École Secondaire St-Jean-Knde Institut Agricole d'Oka.Séminaire de Québec.Collège Laval de St-Vincent de Paul École Supérieure Le Plateau.St.Francis High School.École Supérieure Le Plateau de de Montréal.Collège St-Joseph de St-Kaymoiul.École Supérieure Le Plateau, >!!i| SAINT-FRANCIS Fieri Facias de Terris District of St.Francis Superior Court, (/QUEBEC FARM CRE-N° 19 520.< V-Ç DIT BUREA I , body ^ politic and incorporated, having its corporate seat at Quebec, district of Quebec, plaintiff, vs ROGER BEAUREGARD, farmer, domiciled at Asbestos, county of Richmond, district of St.Francis, defendant, & JEAN ROYr, trustee, Victoriaville, district of Arthabaska, in his quality of trustee to the authorized assignor's properties, present détendant, mis-en-cause.\"1.The cadastral lot No.two \"A\" (2-A) of the fourth range of Shipton and the cadastral lot N° two \"C\" (2-C) of the fifth range of Shipton.Less and to distract from said lot two \"A\" the part sold to the corporation of St-Georges de Windsor, and fully described in the deed registered at Richmond No.50434.2.A strip of land being part of cadastral lot No.two \"B\" (2-B) of the fifth range of Shipton, seated and situate between the south-west line of lot No.2-C and the north-east line of lot Xo.2-D of the fifth range of Shipton, on all the depth of said lot No.2-C.3.A strip of land of twenty-eight feet in width, being part of lot No.two \"B\" (2-B) of the fifth range of Shipton, commending at the south-east corner of lot No.2 \"C\" of the fifth range of Shipton, going in the north-wot direction, following the rear line of said lot Xo.two \"C\" to the south-cast line of lot No.2 \"D\" of same range; thence following the said south-east line of lot 2 \"D\" a distance of twenty-eight feet (28').thence at right angle, in the south-east direction, in straight line to a point that would be the continuance in straight line of the southeast line of said lot No.2 \"C\" and at twenty-eight feet (28') from said line.The whole as formerly occupied by Frederic Labranche.The whole with buildings thereon erected.' To be sold \"en bloc\" at the registry office, in Richmond, WEDNESDAY, the SECOND day of SEPTEMBER 1959, at TEN o'clock in the forenoon.JOSEPH LABRECQUE.Sheriff's Office, Sheriff.Sherbrooke, July the 27th 1959.51131-31-2-0 [First insertion, August the 1st, 1959] TERREBONNE Canada \u2014 Province of Quebec District of Terrebonne Superior Court, f-pHE QUEBEC FARM No.29265.< j- CREDIT BUREAU, vbody politic and corporate. QUEBEC OFFICIA L GAZETTE, Quebec.August 22nd.1959.Vol.91, Xo.34 3373 non'-, avant son siège social à Quebec, demandeur vs |,l GÊNE PAQUETTE, domicilié à Arundel, comté d'Argenteuil, défendeur.AVIS DE VEN'PE a) I.e lot de terre numéro dix-huit A (18a) du rang huit du canton Arundel, des plan et livre de renvoi officiels dudit canton Arundel, contenant une superficie d'environ cent vingt acres, plus
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.