Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 octobre 1965, samedi 16 (no 42)
[" 97' ANNÉE vol.07 \u2014ESI\u2014.N° 42 S411 (kïïMtf ftlïiml/p do Québec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE 18 OCT 1965 Québec, samedi 16 octobre 1965 Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la reine, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est en* voyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel, :{° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dess tus, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sent strictement payables d'avance.68 Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du Ministre des Finances.~° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8 Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans One première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Imprimeur de la reine avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et «l'autre des frais onéreux de reprise.Quebec, Saturday, October 16.1965 Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Parliament Buildings, Quebec.2.Supply advertising copy in the two official languages.When copy is supplied in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Pay cash and before publication for advertising copy according to the rates set forth below, exception when the copy is to be published several times.In that event, the interested party shall pay upon receipt of his account and before the second insertion : otherwise this insertion will be suspended without further notice and without prejudice to the Queen's Printer who will refund any overpayment.5.Subscriptions, price of documents, etc., are payable strictly in advance.0.Remittance must be made to the order of the Department of Finance, by cheque or money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the dead line for receiving notices, documents or advertising copy expires at noon on Wednesday, unless it is a holiday.In that event the dead line is noon, on Tuesday.Notices, documents or advertising copy not received on time will be published in a subsequent edition.Moreover, the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, because of their length or for reasons of administration.8.Any demand for cancellation or any remittance of money is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Publiés par le Gouvernement de la Province / Published by the Provincial Government L'Imprimeur de la reine, ROCH LEFEBVRE, Queen's Printer \u2014 Québec 6412 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre M6t 97' année, No Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 30 cents la ligne ngale, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 10 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: SI des 100 mots.Exemplaire séparé: 40 cents chacun.Feuilles volantes: SI.50 la douzaine.Abonnement: 810 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Imprimeur de la reine, RoOB Lefebvhe.Hôtel du Gouvernement, Québec, S mai 1902.8903 \u2014 1-52-0 Lettres patentes Les Agences Futitra inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 13c jour de septembre 1905, constituant en corporation: Michel Tanguay, agent d'assurances, 942, Monrèse, Claude Gignac, agent d'assurances, 157, Des Saules, est, Emilien Le tarte, garagiste, 3238, 1er avenue, et René Favreau, militaire, 1975, de Grandville, tous quatre de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce d'appareils de reproduction sonore et de communication, et d'articles de bureaux en général, sous le nom de « Les Agences Futura inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 13e jour de septembre 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.12409-o 4054-05 L'Association des employeurs de l'industrie de l'automobile inc.Automotive Industry Employers' Association Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 23e jour d'août 1066, constituant en cor-poration sans capital-actions: Médard Deniger, 100, de Chftteauguay, Longucuil, Sam Kantor, 5559 Queen Mary, Jacques Lalonde, 4411 Pa-pineau, Hyman Rabinoviteh, 183, Netherwood Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 30 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 81 per 100 words.Single copies: 40 cents each.Slips: SI.50 per dozen.Subscriptions: 810 per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first, figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third to the number of insertion, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our trans* hit inn.Notices published but once are followed only by our document number.RoCH LSFBBVRE, Queen's Printer.Parliament Buildings, Quebec, May 5, 1902.S903 \u2014 I 52 .i Letters Patent Les Agences Futura inc.Notice si hereby given that under Part I of the Companies Act, letters patent bearing date the 13th day of September, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Michel Tan-guay, insurance agent, 942 Manrèse, Claude Gignac, insurance agent, 157 Des Saules.East, E nilien Letarte, g rageman, 3238, 1st Ave., and René Favreau, soldier, 1975 de Grandville.all four of Quebec, for the following purposes: To carry on business dealing in apparatus for sound reproduction and communication, and in office equipment in general, under the name of \"Les Agences Futura inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be al Quebec, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of September, 1965.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.12409 4054-85 L'Association des employeurs de l'industrie de l'automobile inc.Automotive Industry Employers' Association Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of August, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Médard Deniger, 100 de Châteauguay, Lontueuil, Sam Kantor, 5559 Quenn Mary, Jacques Lalonde, 4411 Fa-pineau, Hyman Rabinovitch, 183 Netherwood QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, October 10, 100',, Vol.07, So.AjB Crescent, tous quatre hommes d'affaires, Guy Gagnon, avoeat, 5703, Duroelier, Jean H.La-fleiir.avocat, 442, Woodlea, et Ginette Desau-tels, secrétaire, fille majeure, 586, Fleury, est, -i\\ derniers de Montreal, pour les objets suivant.Protéger et développer de toutes manières les intérêts économiques, sociaux et professionnels des membres de la corporation, sous le nom de « L'Association des employeurs de l'industrie île l'automobile inc.- Automotive Industry Employers' Association Inc.».Le siège social de la corjioration sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, i i le jour d'août 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvtlle.12409-0 3745-05 I ' Vssociation des parents des étudiants de Chûteauguay inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie «le la Loi des compagnies, il a été accorde, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 13e jour de septembre 1965, constituant en corporation sans capital-actions: Martin Hardy, agent de relations extérieures.55, rue St-Léon.Gérard Poirier, technicien «le laboratoire, 107.Mc-Comber, Alphonse Falardeau.gérant.13, Normand, et Joseph Duludc.pharmacien, 47, Iwu- levard «l'Anjou, tous quatre de Châteauguay, pour les objets suivants: Grouper les parents des étudiants de Châteauguay, les informer et leur permettre de prendre davantage conscience de leurs obligations et de leurs droits «lans l'oeuvre «l'éducation de leurs entants, sous le nom «le « L'Association «les parents des étudiants «le Châteauguay inc.Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers (pie peut acquérir «'t possédei la eoiporation.est «le 850.000.I.e siège social de la corporation sera à Châ-leauguay-Centre, district judiciaire which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be United, is 850.000.The head office of the corporation will be at Châteauguay-Centre, judicial district of Beauharnois.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of September, 1905.Raymond Dodtille, Assistant Secretary of the Province.12409 1056-65 Atlan Industries, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 10th day of September, L965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Willard .Millican Cliff Steeves, advocate.133 Brownsburg Road.Lachute, Willard Millican Steeves, retired banker, 732 Main Street, Lachute.Robert Armstrong, insurance agent.308 Rosedalc Avenue.Hrownsburg.and Alexander Hamilton Kerr, technician.070 Main Street.Lachute.for the following purposes! To carry on the business of tailors, under the name of \"Atlan Industries, Limited\", with a total capital stock of 840.000.divided into 10,000 common shares of the par value of 84 each.The bead office of the company will lie at 189 Brownsburg Road, Lachute.judicial district of Terrebonne.la**. 5414 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre 1965, 97' année, No Ai Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 10e jour de septembre 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvilmj.12409 4013-65 Automotive Glaims Appruisul Co.Avis es! donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, il a «'-té accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 13e jour de septembre 1005, constituant en corporation: Marcel Béland, évahiateur, Georgette Turcot, ménagère, épouse commune en biens dudit Marcel Béland, «'i dûment autorisée par lui aux lins «les présentes, tous deux de 6940, rue Cartier.et Réjean Menard, garagiste.2001.rue Desjardins, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Evaluer les dommages «\u2022anses aux automobiles, aux yachts et sur l'équipement industriel, sous le nom de « Automotive Claims Appraisal Co.avec un capital total de $10.000.divisé en 100 actions ordinaires «le 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 5940, rue Cartier, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 13e jour «le septembre 1965.Le Sous-secrétaire f the Provincial Secretary, this 10th day of September, 1965.Raymond Dm vii.i.i;.Assistant Secretary of the I'mrii 12109-.) 401 83 Automotive Claims Appraisal Co.Notice is hereby given that under Part 1 of the Companies A«'t.letters patent, bearing date the 13th day of September, 1005, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Provint*) of (Quebec, incorporating: Marcel Behind.e\\alia- tor, Georgette Turcot, housewife, wife comme as to property of the said Marcel Béland.and duly authorised by him for these presents, i>\"tli of 5940 Cartier St.and Rt'jean Ménard, gars* geman, 2601 Desjardins St., all three of Mont< real, for the following purposes: To assess damages caused to automobiles, yachts and industrial equipment, under the name of \"Automotive Claims Appraisal Co.\", with a total capital stock of 810.000.divided into 100 common shares of 8100 each.The head office f the company will be al 5040 Cartier St.Montreal, judicial district of Montreal.Given at tin- office of the Provincial Secretary.this 13th day f September, 1905.Raymond Doivii.i.i.Assistant Secretary of the Province.1240!» - 2891-65 Le Barillet (Jompiière) ltée Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 21st day of September, 1965, nave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Yvon Tremblay, restaurateur.Marguerite (iaudivault.housewife, wife contractually separate as to property of tin* said Yvon Tremblay, and duly authorized by him for these presents, both of 120 Conn elles, and Paul Tremblay, barber.129 de la Normandie, all three of Jonquière.for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Le Barillet (Jonquière) ltée\", with a total capital stock of 840.000.divided into 2,500 common shares of 810 each and 150 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Given at the Office of the Provincial Secretary.this 21st day of September, 1905.Raymond Dor villi:.Assistant Secretary of the Province, 12409 397' 85 Belair Auto Boby & Painting Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Juergen Janus, salesman, George Gador, garage operator, and Mara Mathan, housewife, wife separate as to property of the said George Gador, all three of 5025 Charlevoix, Laval, for the following purposes: To carry on the business as garage-keepers, under the name of \"Belair Auto Body & Painting Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 10,000 common shares of SI each and 300 preferred shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, 1965, Vol.97, No.À» 5415 I.siège social de la compagnie sera 784, lx>u-bvard l*al>elle, Laval, district judiciaire de Moi treat.Donné au bureau du secrétaire de la province, I\u2022,¦ joui* c at Rond Point, Levis, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of September, 1965.Raymond Douvillk, v Assistant Secretary of the Province.12409 404G-65 Blackhawk Paper Waste and Salvage Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Isidore Greenbaum, 615 Westluke, Côte-St-Luc, Aaron Pollack, 1827 North Avenue, Montreal, and Baruch Pollack, 6085 de Vimy Street, Montreal, all tlirec advocates, for the following purposes: To deal in paper, waste and scrap products of all kinds, under the name of \"Blackhawk Paper Waste and Salvage Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common 5410 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 10 (vtolirc 190», 97' année, A'o A2 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, 10,000 actions privilégiées catégorie « A » d'une valeur au pair de $1 chacune et 2,000 actions privilégiées catégorie « Il d'une valeur au pair «le S10 chacune.Ia' siège social de la compagnie sera 1255, rue l'niversity, chambre MO, Slontréal, district judiciaire dé Monlival.Donné au bureau du tecrétaire de la province* «\u2022«¦ 2e jour de septembre 1905.Le Sous-secrétaire de la provinei-, Raymond Douvillk.12400 3063-65 Dave Boxer Knterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi del compagnies il a été accordé, par le lieutenant «gouverneur de la province «le Québec, del lettres patentes, en date du 13e jour de septembre 1905.constituant en corporation: Dave Boxer, annonceur à la radio, 8325, boulevard L'Acadie, app.\"12, Montréal, Hyman Laddie Schnnilicrg.avocat.7100.chemin Kings-ley, app.003, ('ôte-St-Luc, et Irwin Schnail>crg, étudiant en droit, 4835, avenue Mont clair, Montréal, pout les objets suivants: Kxereer un commerce d'agents et de représentants dans les domaines «lu théâtre, «le la radio et «le la télévision et «le réservation «le billets, sous le nom «le « Dave Boxer Kntcrprises Inc.>\\ avec un.capital total «le §40,000, divisé en 2.000 actions ordinaires de S10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 13e jour de septembre 1065.Le Sons-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.12400 4052-05 Le Centre d'art de Percé inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 3c jour «le septembre 1005, constituant en cor|x>ration sans capital-actions: Suzanne Cuite, artiste-sculpteur, Perce*, Madeleine Gauvreau, secrétaire, veuve «lu Dr J.-E.Laforest.1005, avenue Parc, app.5, Québec, et François de Billy Gravel, avocat, 350, chemin St-Louis, Québec, pour les objets suivants: Promouvoir toutes activités culturelles et artistiques, expositions de peinture et sculpture, spectacles de théâtre et activités «le ciné-clubs,, sous le nom de « \\a> Centre «l'art de Percé inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est «le $1,000,000.Le siège social de la corporation sera à Percé, «listrict judiciaire de Gaspé.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 3e jour de septembre 1965.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.12400-o 3984-65 l^e Centre de» études universitaires de Trois-Rivières, inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la shares «>f the par value of $10 ea«*h, 10,000 class \"A\" preferred shares of the par value of 81 eceh and 2,000 class \"B\" preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be ;il 12.').\") l'niversity Street, suite 810, Montreal, ju- dicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day of September, 1905.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Provint-.12409*0 3053-65 Dave Boxer Kntcrprises Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day «>f Septeml»cr, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporotingj Dave Boxer.radio announcer, X325 L'Acadie Boulevard.Apt.712, Montreal, Ilyman Laddie Sclmaiberg.advocate, 7460 Kingsley Roa«l, Apt.903, Cote-St-Luc, and Irwin Schnail>crg, law-stmlcnt.1835 Montclair Avenue.Montreal, for the following purposes: To carry DO the business of theatrical, radio ami television hooking agents and representatives, under the name of \"Dave Boxer Enter prises Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2.000 common shares of 81\" each and 2.000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of September, 1905.Raymond Dor villi.Assistant Secretary of the Province.12400m 4052-65 I a- Centre d'art de Percé inc.Notice is hereby given that under Part 111 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 3rd day of September 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without sliarc capital: Suzanne Guite, artist sculptor, Percé.Madeleine Gauvreau, secretary, widow of Dr J.-K.Laforest, 1065 Park Avenue, app.5, Quebec, and François de Billy Gravel, advocate, 350 St-Louis Road, Quebec, for the following purposes: To foster all cultural and artistic sculpture and painting exhibitions, theatre entertainments ami cine-club activities, under the name of \"Le Centre d'art de Percé inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire an«l hold is to l>e limited, is 81,000*000.The head office of the corporation will be -it Percé, judicial district of Gaspé.Given at the office «>f the Provincial Secretary, this 3rd day of September 1905.RaYMON d DOU villk, Assistant Secretary of the Province.12405» 3984-65 Lc Centre des études universitaires de Trois-Rivii-rcs, inc.Notice is hereby given tliat under Part 111 ol the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of August, 1965,'have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, I960, Vol.97, No.Li 5417 prix incs «le Québec, des lettres patentes, en date du 31e jour d'août 1905, constituant en corpo-talioii sans capital-actions: M.l'abbé Gilles Bou-K :.prêtre, dircctrur général du Centre des Étu-des l'niversitaires, 406, rue Honaventure, Jcan-Ciiv Béliveau, assistant-directeur général du ( lie des Études l'niversitaires, 2731, rue de la Ji nquière, André Brousscuu, secrétaire général du Centre «les Études Universitaires, 1871, rue Père-Daniel, Bernard Lorrain, comptable, .'1910, rue de la Sapinière, Christian Deniers, directeur du Département «les Sciences au Centre «les Ecu-des Universitaires, 1600, rue de LongucuiL Alfred Jacquet, directeur «lu Département «les Sciences de [Education au Centre des Études Universi-¦ >.2115, rue Desjardins, Guy Mathieu, -Rivièrcs, M.le Chanoine Raymond Langcvin, curé «le la Paroisse Saint-Paul, 499, 0e rue, Graml'Mère, Soeur Marie-Ange Lucia, f.j., directrice «le l'Institut Familial Val-Marie, 90, chemin du Passage, Orner Grat-b a, professeur, 399, rue Montplaisir, Fernand I.mouette, pharmacien, 115, chemin «lu Passage, \u2022I Albert Bergeron, électricien, 116, rue Guillet-l tous quatre «le Cap-de-la-Madeleine, Albert Landry, directeur de l'Institut de technologie de Sliawinigan, 655, rue «le la Station, Frère Henri-Paul Cauchon, f.i.c, doyen «lu Collège universitaire, scientifique «le Sliawinigan, 90 rue «les Cèdres, Charles Mills, ingénieur.388, 6e rue, tous trois de Sliawinigan.Yves l huile, directeur général des Ecoles de la Commission Scolaire Régionale Provencherde Nicolet, Nicolet, Maurice La-vallée, marchand.Picrrcville.Dr Avellin Dal-court, médecin, 4.rue Si-Laurent.Louise ville, Léon ( iervais, chimiste, 550.avenue «lu Coteau.La Tuque, et Bertrand Lebel, agronome et cultivateur, Canton «le Kingscy (St-Félix-de-King-sey), pour les objets suivants: Etablir, maintenir et administrer un Centre «le-* études universitaire, sous le nom de « Le Centre des études universitaires de Trois-Rivières, inc.».Le montant auquel sont limités les biens im-mobiliers que peut acquérir et possé«ler la corporation, est de 810,000,000.Le siège social de la cor|X)ration sera à Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières.\u2022 tonné au bureau du secrétaire de la province, ce 31e jour d'août 1965.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.12409-0 3677-65 been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quel>ec, to incor|Miratc as a corporation without sluire capital: Father (idles Boulet, priest, director general of ( 'entre «les Études Universitaires, 466 Bonaventure st., Jean-Guy Béliveau, assistant director general of Centre des Études Universitaires, 27.31 de la .lompiière St., André Brotisscau, secretary general of Centre des Études Universitaires, 1871 Père-Daniel St.Bernard Ijorrain, accountant, 3910 «le la Sapinière St., Christian Demers, director of the Science De(>artmcnt at ('«Mitre des Éludes Universitaires, 1600de LongUeuilSt., Alfred Jacques, director of the Science of Education Department at ('«'litre des Études Universitaire.2415 Des-jardins St., Guy Mathieu, director of the Commerce and Special Courses Department at Centre «les Études Universitaires, 4235 Bouleaux St.Father Rcynahl Rivard, priest, psychologist, 1337 du Carmel Blvd., Maurice Borduas, director of the Department of Lettres at Centre «les Etudes Universitaires, 3705 Papincaii St., Canon AI bani Melanism, Superior of Séminaire St-Jo-sepb, Séminaire St-Joseph, Laviolette St., Father Louis Martel, Director of Studies at Séminaire St-Joseph, Séminaire St-Joseph, Laviolette St.Father Louis Massicot tc, Principal of Maurice L.Duplessis Norman School, 3175 Laviolette Blvd., both priests.Rose Beaudoin, housewife, wife of Lews AJlyson, 1301 Jean-Nicolet St., Henri Perron, chartered accountant, 118 Radis-son St., Dr.J.-A.Denoneuurt, physician, 329 Laviolette St., Richard Rioux.advocate, 1581 Royale St., Roland Martel, regional director of Confédération «les Syndicats Nationaux, 983 Royale St., all seventeen of Trois-Rivières.Canon Raymond Langcvin, pastor of Saint-Paul Parish.499, 6th St., (iraml'Mèrc, Sister Marie-Ange Lucia, f.j., directress of Institut Familial Val-Marie, 90 du Passage Road, Omer Gratton, professor, 399 Montplaisir St., Fenians] Lanouct-te, pliarniacist, 115 «lu Passage Roa«l, J.-Albert Bergeron, electrician, 110 Guillettc St., all four of Cap-f schools in the Provencher Regional School Board in Nicolet, Nicolet, Maurice Lavallee, merchant, Pierrcvil-le, Dr.Avellin Dalcourt.physician.4 St-Laurent St.Louiseville, Léon Gervais, chemist.550 du Coteau Ave.La Tmpie.ami Bertrand Lebel.agronomist and farmer.Township of Kingscy, ( S t - Fé I i x - de-Kingsey), Cor the following purposes: To establish, maintain and manage a University Study Center, under the name of \"Le Centre «les études universitaires «le Trois-Rivières, inc.\".The amount to which the value of the immov-vcable property which the corporation may acquire and hold is to l>e limited, is 810,000,000.The head office of the corporation will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Given at the office of the Provincial Secretary, this 31st day of August, 1965.Raymond Douvillk, .Issi.stuut Secretary of the Province.12409 3677-65 'Alb GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 10 octobre 19(iû, 97' année, No L> Centre de vitres de Montreal inc.Class Centre of Montreal Inc.Avis est donné qu'on vertu de la première partie «!«\u2022 la Loi des compagnies de Québec, il a «\u2022té accordé, par le lieutenant-gouverneur ant Vendôme, Dr Jacques Lefebvre, médecin, 3200, Renoir, «-t Jacques Lapointe, représentant, iiisô.D'AuteuiL tous trois de Laval, pour les objets suivants: L'air»- l«' commerce du verre «\u2022! de bous ses produits et sous-produits, sous le nom de ' Centre «le vitres de Montréal inc.Glass Centre of Montreal Inc.avec un capital total de $40,000, divisé «-il 2,500 actions ordinaires de 810 chacune et en 1,500 actions privilégiées «le 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont réal-nord.district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 8e jour de septembre 1965.I.c Sous-secrétaire ck «>f 840,000, divided into 1.000 common shaies «>f 810 each and 3.000 preferred shares of 810 each.The head office «>f the Company will he at Baie-Comeau, judicial district of Hauterive.(îiven at the office »»f the Provincial Secretary, this 0th day of S»-ptemlH'r, 1965.Raymond Douvtixk, Assistant Secretary of the Provinct 12400 3041-05 Charme & beauté Lise Watier inc.Notice is hereby given that under Part 1 the Quebec Companies Act, letters patent.bearing «late the 3rd day «>f September, 196 have been issued by the Lieutenant-(io\\cru> «)f the Province of Quebec, incorporating: Lise Watier.artist, fille majeure, Jacques Watier.salesman, both «>f 200 Dubeau, Si-Laurent, ami Bernard Sauvageau.trader.8440 Wav«-rl> Montreal, f«u* the following purposes: To give courses and conferences on the following subjects: beauty, charm, elegance, etiqUetli and mannequin, dancing, decorating and paint ing, upkeeping of a house ami cooking, undei QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October Hi, mo, Vol.07, No.AM ,,!ec Companies Act.letters patent, 5422 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre 1965, 97' année, No A2 été accordé, par le lieutéiuuit-gouverneur «l«* la province «le Qiu'd >«\u2022«\u2022.des let tics patentes, en date du -le jour de juin 1965, constituant en corporation: Claude Beaulieu, 279, St-Édouard, (¦uiinont Beaulieu, 12.bouh-v/trd Bernard, tous ilcux de Druimnondvillc-Ouest.et Serge Menard.I H »o.boulevard Saint-Joseph.Drummondville- Sud, tOUS trois industriels, pour les objets suivants: Faire affaires connue constructeura et «'litrepreneurs généraux en const ruction, sons le nom de «Construction Beaulieu & Menard ltée Beaulieu & Ménard Construction Loi.avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la Compagnie sera à Driuu-mondvilie.district judiciaire de Drununond.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 16e jour de septembre 1965.l.< Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvilus.I2409-O 2661*65 Corporation de développement et prêts de Montréal ltée Avis est donné qu'en vertu «h- la première parti»- de la Loi des compagnies, il a «;lé accordé, par le lieutenant-gouverne.ur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 15e jour de septembre 1965, constituant en corporation : Raymond Crevier.2930, avenue Lacombe, Montréal, Pierre Lcgrand, llô.Place d'Amiens, Laval, Louis-Yves Portier, 40, avenue Arlington, West-mont, Michel A.Gngnon.'{70!».avenue Grey, Montréal, Claude Fontaine, 616, avenue Victoria.St-Lamberl.Jacques Laurent.105, rue Marcotte, St-Laurent, «-t Paul Fortin.153:5.avenue McGregor, Montréal, tous sept avocats, ' pour les objets suivants: Paire affaires comme compagnie «le prêts, «l'exploitai ion de terrains et de financement, sous le nom de « Corporation «le développement «'t prêts \u2022\">.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Daniel Morris, advocate, 6165 Notre-Dame-de-Grâcc Avenue, Montreal, Phyllis Stern, secretary, til le majeure, 3250 Ellendale, Montreal, Irving Ha! perin, advocate, 5600 Queen Mary, Hampstead, and Georgette Lavoie, secretary, fille majeure, 217 Georges-Vanier Street, Laval, for the following purposes: To operate radiology clinics and provide all services normally provided by qualified radiologists, under the name of \"Côte des Neiges B t-diological Centre Inc.\", with a total capita! stock of $50,000, divided into 1,000 common shares of S10 each, 3,900 class \"A\" preferred shares of S10 each and 1,000 class \"B\" preferred shares of SI each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, 1065, Vol.07, No.6423 ¦-\u2014¦\u2014\u2014\u2014\u2014-\u2014-\u2014- Le si deal in bread, cakes, pastry ami ail articles «>f food produced by baking ami t«> carry on the business of restaurateurs, uiuler the name of \"The Donut Chef Inc.I^es Bcignes «lu Chef inc.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 2,000 common shares of S;|(( each and 2,000 preferred shares or $io each.The head office of tin- company will be ;tt Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of tin- Provincial Secretary, this 10th f $100 each.The head office of the company will be al Montreal, judicial «listrict of Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of September.1905.Raymond Doivilli:.Assistant Secretary of the Province.I2409-o ( 4028-65 Maurice Dumais inc.Notice is hereby given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of Septeml)cr, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Maurice Dumais, industrialist, Cécile Simard, housewife, wife contractually separate as to property of the i QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October Hi, 1905, Vol.97, No.J0 5425 parée de biens dudit Maurice Dumais, et Antoine Dumais, rentier, tous trois de Hauterive, pour les objets suivants: Paire le commerce de bières, eaux gazeuses, eaux minérales, liqueurs douces, eau de javel mi autres nettoyeurs, sous le nom de « Maurice Dumais inc.», avec un capital total de §20,000, dit isé en 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Hauterive, district judiciaire de Hauterive.I tonné au bureau du secrétaire de la province, ce 13e jour de septembre 1005.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.12409*0 4057-05 Dynamic Welding Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a élé aeconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en «late du le jour d'août 1965, constituant en corporation: Jacques Dorris, surintendant, 7192, Pontoise, St-Léonard, Kurt Walther, contremaître, 4100, Broa«lway, app.10, Lachine, Gerhard Gohrt, contremaître, 1433, Robillard, La-lli'chc.Vito Fundaro, ajusteur, 2290, avenue Wilson, et Eugène Rrouillet, avocat, 6502, Christophe-Colomb, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de soudure, sous le nom de « Dynamic Welding Co.Ltd.», avec un capital total de §40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.I.e siège social de la compagnie sera 2110, rue Bennett, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce le jour d'août 1965.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.12406 3453-05 Dynatrust Ltd.\\\\i> est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en «late du I'm- jour «le juin 1905.constituant en corporation: Herbert Birkett McNally.Paul Frederick Dingle.Vincent-François Lefebvre, Frederick William Benn et Bernard-André R«>y, tous les cinq avocate, «le 507.place «l'Armes, Montréal, pour les objets suivants: Exercer les commerces de conseillers en finance, industrie et gestion, SOUS le nom de « Dynatrust Ltd.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 10.0(H) actions ordinaires de $1 chacune et oil.000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29e jour de septembre 1905.Le Sous-seerétaire de la province, Raymond Doivillk.12409 2648-65 L'Ecole Commerciale Côté inc.Avis est donné «m'en vertu «le la première partie de la I,oi des compagnies, il a été aeconlé.par |«- lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en «late du 9e jour «le septembre 1965.constituant en corporation: said Maurice Dumais, and Antoine Dumais, annuitant, all three of Ilautcrivc, for the following purposes: To carry on business dealing in beer, sparkling waters, mineral waters, softdrinks, Javel water or Other cleansers, under the name of \"Maurice Dumais inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 common shares of $100 each.The head office of the company will l>e at Hauterive, judicial «listrict of Hauterive.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of September, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.12400 4057-05 Dynumie Welding Co.Ltd.Notice is hereby given that uiuler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of August, 1905, have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Dorris, superintendent, 7192 Pontoise, St-Léonard, Kurt Walther, foreman, 4100 Broadway, Apt.10, Lachine, Gerhard Gohrt, foreman, 1433 Robil-lanl, Laflèche, Yit«> Fundaro, assembler, 2290 Wilson Avenue, and Eugène Brouillct, lawyer, 0502 Christophe-Colomb, the latter two of .Montreal, for the following purposes: To operate a soldering business, under the name of \"Dynamic Welding Co.Ltd.\", with a total capital Stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 2110 Bennett Street, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of August, 1905.Raymond Douvilue, Assistant Secretary of the Province.12409-.) 3453-65 Dynatrust Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent.lH'aring date the 15th day of June.1905, have been issued by the Lieutenant-(îovernor of the Province of Quebec, incorporating: Herbert Birkett McNally.Paul Frederick Dingle.vincent-Francois Lefebvre.Frederick William Benn ami Bernard-André Roy.all five advocates, of 507 Place d'Armes, Montreal, for the following purposes: To carry on the businesses «>f financial, industrial ami management consultants, under the name of \"Dynatrust Ltd.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 10,000 common shams of $1 each and 30.000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will l>e at Montreal, judicial «listrict of Montreal.(ïiven at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of September.1965.Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.12409-n 2648-65 L'École Commerciale Côté inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 9th day of September, 1905.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Fernand Cormier, pre* 5420 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 10 octobre 1905, 97' année.No 12 Pernand Cormier, proesseur, Madeleine Denis, institutrice, épouse contrectuelleinent séparée «I»' biens dudil Feraeud Cormier, et dûment autori- set- par lui aux lins de présentes, tous deux de 74, Radison, et Douai Côté, professeur, -122.Bono* venture, tous trois de Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exploiter un collège ou institution d'enseignement commercial, ^>us le nom de * L'Ecole Commerciale Côté inc.avec un capital total île $40,000, divisé en 50 actions ordinaires de mou chacune et en .'{50 actions privilégiées de siuil cba.une.Le siège social «le la compagnie sera 1200.rue Notre-Dame, Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières, Donne au bureau du secretaire de la province, ce 9e jour de septembre 1965.le Sous-secrétaire de la province, Raymond DouVILLE.12400*0 1004-65 Les Edition» D.B.F.ine.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 15e jour de septembre 1005, constituant en corporation: Jacques Fortin, journaliste, Gisèle Champagne, ménagère, épouse séparée de biens dudit Jacques Fortin, et Marie-Anne Drouin, ménagère, épouse séparée de biens de Hervé Fortin, tous trois de St-Georgcs, j>our les objets suivants: Faire atl'aires comme imprimeurs et éditeurs, sous le nom de « Les Éditions D.IL F.inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Georges, district judiciaire de Beauoe.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 15e jour de septembre 1905./.«¦ Sous-secrctairc de la province, Raymond Dolville.12409-o 4102-05 Les Editions Fani inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 20e jour d'août 1905, constituant en corporation: Gilles Juteau, avocat, G387, Viau, Claude Quidoz, avocat, 7922, Papineau, et Pierrette Mois-.m, avocat, fille majeure, 1410, Aird, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme éditeurs et imprimeurs, sous le nom de « Les Éditions Fatal inc.», avec un capital total de §50,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et en 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour d'août.1005.Le Sous-secrétaire de la province, R aymon d DOU ville.12409-O 3719-05 Aux Elégants importations inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a été aeconlé1.par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 15e jour de septembre 1905.constituant en eorpo- fesSOr, Madeleine Denis, teacher, wife COntrae.tunlly separate as to property of the said Fer-nand Cormier, ami duly authorized by him these present, both of 7 1 Radisou.aud Douai ( 'fité, professor, 322 Bonnventure, all three of 'run.Rivières, for the following purposes: To operate a college or institution of commercial learning, under the name of \"L'École Coin, nicreialc Côté inc.\", with a total capital *tock of .810.000.divided into 50 common shares of S100 each and 350 preferred shares of $100 each.The head ollicc of the company will Ik ,,i 1200 Notre-Dame St.Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Given at the office of the Provincial Secretary, Ibis «Mh day of September.1005.Raymond Dor villi .Assistant Secretary of the Province.1210!» 1004-65 Les Éditions D.H.F.inc.Notice is hereby given that under Pari I .f the Companies Act, letters patent, bearing lale the 15th day of September, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Fortin, journalist, Gisèle Champagne, housewife, wife separate as to property of the said Jacquc- Fortin, and Marie-Anne Drouin, housewife, wife separate as to property of Hervé Fortin, all three of St-Gcorges, for the following purposes: To carry on business as printers and editors, under the name of \"Les Éditions D.B.F.inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at St-Georges, judicial district of Beauce.Given at the ofliee of the Provincial Secretary, this 15th day of September, 1905.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Provinci.12409 4102-65 Les Éditions Fam inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quel>ec Companies Act, letters patent, l>earing date the 20th day of August, 1905, have l>ecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gilles Juteau, advocate, 0387 Viau, Claude Quidoz, advocate, 7922 Papineau, and Pierrette Moisan, advocate, fille majeure, 1410 Aird, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as editors and printer-, under the name of \"Les Éditions Fam inc.\".with a total capital stock of $50,000, divided into 200 common shares of $100 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of August, 1965.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.12400 8719-65 Aux Élégants importations inc.Notice is hereby given that under Part I ol the Companies Act, letters liaient, bearing date the 15th day of September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Salomon QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, I960, Vol.97, No.L2 5427 ration: Salomon Medalsy, Titi Lallouz, épouse commune en biens dudit Sulomou Medalsy, tous id- (1915, Wilderton, ft Marc Medalsy, 2000, avenue Kent, tous trois marchands, de Montreal, pour les objets suivants: Manufacturer et négocier des articles vestimentaires, accessoires et autres marchandises, min- le nom de « Aux Elégants importations inc.avec un capital total de $10,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2.0(H) actions privilégiées de $10 chacune.|,e siège social de lu compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce I.V jour «le septembre 1905.Le Sous-secrétaire de lu province, Raymond Doivillk.12409 4092-65 Entreprises Lopack liée Lopack Enterprises Ltd.Avis est donné (m'en vertu de la première pailie de la Loi tics compagnies de Quebec, il a et- accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 2e jour de septembre 1005.constituant en corporation : (iérald Lafortune, entrepreneur.171.boulevard Kiel.Hull, David Brosseau, homme d'affaires, et Gertrude Charette, ménagère, épou-conmume en biens dudit David Brosseau.ces ileux derniers de l'ortage-dii-Forl.pour les objets suivants: l'aire all'aires comme compagnie d'immeuble, de construction et de placement, sous le nom de Entreprises Lopack liée Lopack Enterprises Ltd.avec un capital total de 140,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et eu 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Hull, district judiciaire de Hull.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 2e jour de septembre 1005.I.c Sous-secrétaire de lu province.Raymond Dou ville.12-109-o 3574-05 Ferrât te inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date ¦lu 3le jour d'août 1965, constituant en corporation: Lydie L.Dumais.secrétaire, épouse conlractuellement séparée de biens de Yvon Dumais.Jean-Yves Bernatchez, comptable agréé, et Guy Bernatchez, comptable agréé, tous trois «le Hauterive.pour les objets suivants: Paire all'aires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de Ferratte inc.», avec un capital total de $20.000, divisé en 2.000 actions ordinaires de $1 chacune et en 1,800 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Baie-I ouicau, district judiciaire de Hauterive.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 31e jour d'août 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doivillk.12400-q 3870-05 Fiala The Jeweller Inc.Le joaillier Fiala inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I^oi des compagnies de Québec, il a Medalsy, Titi Lallouz, wife in community of the sais Salomon Medalsy.both of 0915, Wildertoii.and Marc Medalsy, 2000, Kent Avenue, all three merchants, of Montreal, for the following purposes : i To manufacture and deal in wearing apparel, accessories and other merchandise, under the name of \"Aux filé-gants importations inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 2.0(H) common shares of $10 each and 2.000 preferred shares of $10 each.The head ollicc of the company will lie at Montreal, judicial district of Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of September, 1905.raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.l'2409-o 4092-05 Entreprises Lopack ltée Lopack Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of September, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: (iérald Lafortune, contractor.171, Kiel Boulevard.Hull, David Brosseau, businessman, and Gertrude Charette.housewife, wife common as to property of said David Brosseau, the latter two of Porlage-du-Fort, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction and investment company, under the name of \"Entreprises Lopack liée \u2014 Ix>pack Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head ollicc of the company will be at Hull, judicial district of Hull.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day of September, 1905.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.12409 3574-05 Fcrratte inc.« Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of August.1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Lydie L.Dumais.secretary, wife contractually separate as to property of Yvon Dumais.Jean-Yves Bernatchez, chartered accountant, and Guy Bernatchez.chartered accountant, all three of Hauterive, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Ferratte inc.\", with a total capital stock of $20.000, divided into 2,000 common shares of $1 each and 1,800 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Baie-Comeau.judicial district of Hauterive.Given at the office of the Provincial Secretary, this 31st day of August.1905.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.1240») 3870-05 Fiala The Jeweller Inc.Le joaillier Fiala inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Queliec Companies Act, letters patent. 5-128 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre 1965, 97' année.No |f été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, dee lettres patentes, en «late du 27e jour d'août 1065, constituant en corporation : A.Arnold Lechter, avocat, 5701, Blossom, Cote-St-Luc, Lynn Steinberg, secrétaire, célibataire, 5060, Souari.Montréal, et Rose-Marie Weissman, secrétaire, célibataire, 7021, VVavell, ('ôic-Si-I.uc.pour les objets suivants: Manufacturer «les bijoux et produits connexes et en faire le commerce, sous le nom de « Fiala The Jeweller lue.Le joaillier Fiala inc.avec un capital total de % 10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SKI chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Ia' siège social de la compagnie sera 51 Si, chemin Cote-des-Neiges, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 27e jour d'août 1065.Le Soue-aecrétaire de la province.Raymond Douvillk.12400 3847-65 G & A Service Station Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 27e jour d'août 1005, constituant en corporation: Adalbert Gerbitz, propriétaire d'un poste de service, 11020, boulevard L'Acadie, Montréal, George Pichner, mécanicien, 11545, Ovila-lioucher, Montréal Nord, et Stanley, Goldberg, comptable agréé, 453, 07e avenue, Laval, pour pes objets suivants: Faire le commerce de véhicules automobiles et agir comme garagistes, sous le nom de « G & A Service Station Ltd.», avec un capital total de $40,000, divise en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Kirk-land, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 27e jour d'août 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.12409 3831-05 Lionel Gagnon et fils inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 8e jour de septembre 1965, constituant en corporation: Lionel Gagnon, commerçant, Claude < ingnon, commerçant, et Véronique Massi-cotte, commerçante, épouse séparée, de biens dudit Lionel Gagnon, tous trois de 1250 10e avenue, Grand'Mère, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Lionel Gagnon et fils inc.», avec un capital total de $15,000, divisé en 250 actions ordinaires de $10 chacune et en 250 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sliawinigan, district judiciaire de St-Maurice.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce Se jour de septembre 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.12409-o 3971-65 bearing dale the 87th day of August, 1965, have been issued by the Licutcnant-(iovernor of the Province of Quebec, incorporating: A.Arnold Lechter, advocate, 5701 Blossom, Cote-St-Luc, Lynn Steinberg, secretary, spinster, 5050 Souart, Montreal, ami Rose-Marie Weissman.secretary, spinster.7021 W'avcll.Cote-St-Luc, for 'la-following purposes: To manufacture and deal in jewellery and allied products, under the name of \"Fiala ; i Jeweller Inc.\u2014 Le joaillier Fiala inc.\".witl a total capita] stock of 140,000, divided into I.OQ0 common shares of $10 each and 3.000 preferred shares of $10 each.The head ollicc of the company will be at 5181 Cote-des-Neiges Road, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the ollicc of the Provincial Secretary, Ibis 27th (lay of August, 1005.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.12I00-.» 3847-65 G & A Service Station Ltd.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of August, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Adalbert Gerbitz, service station operator, 11920 L'Acs* die Boulevard, Montreal, George Pichner, mechanic, 11545 Ovila-Boucher, Montreal North, and Stanley Goldberg, chartered accountant, 453, 07th Avenue, Laval, for the following purposes: To deal in motor vehicles and to do business m garage-keepers, under the name of \"G & A Service Station Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Kirkland, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of August, 1905.Ray.\\iox d Douvi lle, Assistant Secretary'of the Province.12409-o 3831-65 Lionel Gagnon et fils inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, I tearing date the 8th day of September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Lionel Gagnon, trader, Claude Gagnon, trader, and Véronique Massicotte, trader, wife separate as to property of the said Lionel Gagnon, all three of 1250, 10th Ave., Grand'Mère, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Lionel Gagnon et fils inc.\", with a total capital stock of $15,000, divided into 250 common shares of $10 each and 250 preferred shares of $50 each.; The head office of the company will be .I Sliawinigan, judicial district of St.Maurice.Given at the office of the Provincial Secretary, this 8th day of September, 1905.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.12409 3971-'\"- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, I960, Vol.97, No.k2 5429 Curugc Morin & Desmeules inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a ,-U accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec, des lettres patentes, en date du 8e jour de septembre 1965, constituant en corpora! ion: Marcel Desmeules, garagiste, 198, St> Jérôme, Jonquière, Jean-Marie Morin, garagiste, 172, rue Bagot, et Marguerite Jean, ménagère, épouse dudit Jean-Marie Morin, 172, rue Hagot, ces deux derniers de Bagotville.pour les objets suivants: Paire le commerce de véhicules automobiles et faire all'aires comme garagistes, sous le nom de « Garage Morin & Desmeules inc.», avec un capital total de 850,000, divisé en 500 actions ordinaires de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 192, houle-van l St-Anicet, Hagotville, district judiciaire «le Chicoutimi.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce Se jotir de septembre 1005.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.12 H19-0 3698-05 Grande Côte Gardens Inc.Jardins Grande Côte inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Loi tics compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 3e jour de septembre 1905, constituant en corporation: Irving L.Adressky, 50, place Heath, Ilampstesd, Daniel Kingstone, 49S5, avenue Iona, et Braham L.Campbell, 4530, Côte-des-Neiges, app.400, ces derniers de Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, de construction et de placements, sous le nom de « Grande Côte Gardens Inc.\u2014 Jardins Grande Côte inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.I* siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce !5e jour de septembre 1965.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.12409 3949-05 Hébert et Langlois ltée Avis est donné qu'eu vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du se jour d'avril 1905, constituant en corporation: Stanislas Hébert, assureur-vie, Yvette Hébert, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Stanislas Hél>crt, tous deux de 48, Nicolas-Viel, Magog, Jean-Louis Langlois, administrateur, et Lucille Langlois, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Jean-Louis Langlois, ces deux derniers de 328, Collège, Magog, pour les objets suivants: l'aire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Hébert et Langlois ltée », avec un capital divisé en 1,000 actions sans valeur nominale.Le siège social de la compagnie sera à Magog, district judiciaire de St-François.Garage Morin & Desnieules inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, heaving date the 8th day of September, 1905.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Marcel Desmeules, garageman, 193 St-Jérôme, Jonquière, Jean-Marie Morin, garageman, 172 Hagot St., and Marguerite Jean, housewife, wife of the said Jean-Marie Morin, 172 Bagot St.the two latter of Hagotville, for the following purposes: To carry on business dealing in motor vehicles, and to act as garagemen, under the name of \"Garage Morin & Desmeules inc.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 500 common shares of S100 each.The head office of the company will be at 15)2 St-Anicet Blvd., Bagot ville, judicial district of Cliicoutimi.Given at the office of the Provincial Secretary, this 8th day of September, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.12400 3698-05 Grande Côte Gardens Inc.Jardins Grande Côte inc.Notice is hereby given tliat under Part I of the Quel>ec Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of September, 1905, .have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Irving L.Adressky, 50 Heath Place, Hampstead, Daniel Kingstone, 4985 Iona Avenue, and Braham L.Campbell, 4530 Côte-des-Neiges, Apt.406, the latter two of Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Grande Côte Gardens Inc.\u2014: Jardins Grande Côte inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 3rd day of September, 1965.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.12409-o 3949-65 Hébert et Langlois ltée Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of April, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Stanislas Hébert, life insurer, Yvette Hél>ert, housewife, wife contractually separate as to property of the said Stanislas Hébert, both of 48 Nicolas-Viel, Magog, Jean-Louis Langlois, administrator, and Lucille Langlois, housewife, wife contractually separate as to property of the said Jean-Louis Langlois, the two latter of 328 Collège, Magog, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Hébert et Langlois ltée\", with a capital stock divided into 1,000 shares of no nominal value.The head office of the company will l>e at Magog, judicial district of St-Francis. 6430 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre I960, 97' année, No L2 Donné un bureau du secrétaire de la province, 06 17e Jour «le septembre 1005, Le Soux-xccrttaire de la province, Raymond Douvillk.12409-u 1640-65 Hôpital St-Vincent «le Paul de Sherbrooke Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi «les compagnies de Quél>ce, il a été aeconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du Se jour «le septembre 1005, constituant en corporation sans capital-actions: Dr (îéruld Bcnudry, 2415, Portland, Dr Paul Chevalier, 115, Liège, Dr Fernand Tanguay, 100, Murray, tous trois médecins, Jean-Guy Blanchette, avocat, 422, Victoria, Armand Hébert, comptable, 1415, Portland, RoIktI Jussaume, agent «le fiducie, 1575, chemin Beckett, Lucien Lavigne, imlustriel, 300, Carillon.Mu-bel Normandiu, ingénieur, 2055.Vermont, et Georges Sylvestre, notaire, 122, Murray, tous neuf de Sherbrooke, pour les objets suivants: Etablir et diriger un hôpital public situé à Sherbrooke, sous le nom de « Hôpital St-Vincent «le Paul de Sherbrooke \u2022 Le montant auquel est limitée la valeur «les biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $50,000,000.Le siège social «le la corporation sera 300, rue King, est, Sherbrooke, district judiciaire «le St-François.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce Se jour de septembre 1005.Le Soux-xccrétaire de la province, Raymond Douville.12409-o 3872-05 11 > mu- Industrial Complex Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en date «lu 13e jour de septembre 1965, constituant en corporation: Baruch Pollack, 6085, «le Vimy, Aaron Pollack, 1S27, avenue North, tous deux de Montréal, et Isidore Greenbaum, 615, Westluke, Côte-St-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie d'immeubles, construction et placements, sous le nom de « Hymns Industrial Complex Inc.», avec un capital total de 8750, divisé en 120 actions ordinaires «l'une valeur au pair de $5 chacune et 150 actions privilégiées de 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1010, rue Ste-Catherinc ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 13e jour de septembre 1005.Le Sovx-xecrétaire de la province, Raymond Dou ville.12409 4000-05 Ida-Lynne Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 3e jour «le septembre 1965, constituant en corporation: Donald W.Seal, 371, Alexis Nihon, Saint-Laurent, Gary Moseowitz, 260, St-Aubin, Saint-Laurent, et Philip Shaposuick, 5485, Cool-hrooke, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Given at the office of the Provincial Secretary, this 17th day of September, 1005.Raymond Douvillk, Axxixtant Secretary of the Province.12400 1646MW Hôpital St-Vincent de Paul de Sherbrooke Notice is hereby given that umler Part III f September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Dr.Gerald Beaudry, 2415 Portland, Dr.Paul Chevalier, 415 Liège, Dr.Fernand Tanguay, 100 Murray, all three physicians, Jean-Guy Blanchette, advocate, 422 Victoria, Armand Hélart, accountant, 1415 Portland, Robert Jussaume, trust agent, 1575 Beckett Road, Lucien Lavigne, industrialist, 300 Carillon, Michel Normandin, engineer, 2055 Vermont, and Georges Sylvestre, notary, 122 Murray, all nine of Sherbrooke, for the following purposes': To establish and direct a public hospital filiated at Sherbrooke, umler the name of \"Hôpital St-Vincent «le Paul «le Sherbrooke\".The amount to wdnch the value of the immoveable property wdnch the corporation may ac-quire ami hold is to be limited, is $50,000,000.The head office of the corporation will be at 300 King Street East, Sherbrooke, judicial district of St-Francis.Given at the office of the Provincial Secretary, this St h day of September, 1905.Raymond Dou villi:.Axxixtant Secretary of the Province.12409 3872-65 Hjmus Industrial Complex Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of September, 1905, liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Baruch Pollack, 0085 de Vimy, Aaron Pollack, 1827 North Avenue, both of Montreal, ami Isidore Greenbaum, 015 Westluke, Côte-St-Luc, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business t>f a real estate, construction and investment company, under the name of \"Hymus Industrial Complex Inc.\", with a total capital stock of 8750, divided into 120 common sliares of the par value of 85 each and 150 preferred shares of 81 each.The head office of the company will be at 1010 Ste-Catherine Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of September 1905.Raymond Douville, Axxixtant Secretary of the Province.12409-o 4066-65 Ida-Lynne Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quelle Companies Act, letters patent, bearing date the 3r«l day of Septeml>er, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quel>ec, incorporating: Donald W.Seal, 371 Alexis Nihon, Saint-Laurent, Gary Moscowitz, 200 St.Aubin, Saint-Laurent, and Philip Shaposnick, 5485 Coolbrooke, Montreal, all three advocates, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, I960, Vol.97, So.J,J 5131 Fain- le commerce de vêtements, chaussures, gacs à main, tissus, bijouterie, parfums, articles de nouveauté, marchandises en cuir et articles vestimentaires de toutes sortes, sous le nom de * Ida-Lynne Inc.», avec un capital total de 140,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de SI chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 72, Westminster Nord, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, m 3e jour de septembre 1965,, Le Sous-secrHaire de la province, Raymond Douville.4027-65 Les Immeubles Côté inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 15e jour de septembre 1005, constituant en corporal ion: Gérard Côté, importateur-grossiste, Ga-hriclle Lclicl, ménagère, épouse séparée de biens din ht Gérard Côté, et Jacques Côté, étudiant, tous trois de Rivière-du-Loup, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Les Immeubles ( Y>té inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rivière-du Loup, district judiciaire de Kamouraska.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 15e jour de septembre 1005.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.12409-O 4018-65 Les Immeubles Miko inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Quélwc, des lettres patentes, en date du 30e jour d'août 1905, constituant en corporation: Jacqueline Giroux, secrétaire, fille majeure, 2742, Canardière, Quél>ec, Philippe Joli-coeur, notaire, 1016, Rouville, et Pierre-Paul Côté, notaire, 772, Place Philippe, ces deux derniers de Ste-Foy, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Les Im-meubles Miko inc.», avec un capital total de §100,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune et en 000 actions privilégiées de $100 chacune.[ Le siège social de la compagnie sera 040, rue St-Jean Québec, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30c jour d'août 1905.Le Sous-secrHaire de la province, Raymond Douville.12409-0 3834-65 Imprimerie Normandie ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er- jour de septembre 1905, constituant en corporation: Claudette Chouiuard, secrétaire, To deal in clothing, shoes, handbags, furs, fabrics, jewellery, perfume, novelties, leather goods and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Ida-Lynne Inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 4,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred sluircs of S10 each.The head office of the company will be at 72 Westminster North, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 3rd day of September, 1905.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.12409-e 4027-1 i5 Les Immeubles Côté inc.Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of September, 1065, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gérard Côté, importer-wholesaler, Gabrielle Lellcl, housewife, wife separate as to property of the said Gérard Côté, and Jacques Côté, student, all three of Rivière-du-Loup, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Les Immeubles Côté inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 1,000 common shares of 8100 each.The head ollice of the company will be at Rivière-du-Loup, judicial district of Kamouraska.Given at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of September, 1905.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.12409 4018-65 Les Immeubles Miko inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of August, 1065, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacqueline Giroux, secretary, fille majeure, 2742 Canardière, Quebec, Philippe Jolicoeur, notary, 1610 Rouville, and Pierre-Paul Côté, notary, 772 Place Philippe, the latter two of Ste-Foy, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Les Immeubles Miko inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 400 common shares of $100 each and into 600 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 040 St-Jolm Street, Quebec, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of August, 1905.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.12409 3834-65 Imprimerie Normandie ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Claudette Chouinard, secretary, fille majeure, 1465 5432 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 16 octobre 1966, 97' année, Xo Jh> fille majeure, 14(55, Filion, St-Laurent, Jacques Bélisle, imprimeur, 22, Jubinville, et Pierre Thomas, avocat, 250, Des Écores, ces deux derniers de Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeurs, sous le nom de « Imprimerie Normandie liée », avec un capital total de «10,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de 810 chacune et en 250 actions privilégiées de §100 chacune.Mi siège social de la compagnie sera à Laval, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour de septembre 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.12409-0 3863-65 J & K Air Conditioning Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 14e jour de septembre 1965, constituant en corporation: François Payette, avocat, 9029, boulevard Gouîn ouest, Saraguay, Jacqucs-L.Auger, avocat, 8402, rue Drolet, Montréal, et Jean-Guy Lalande, notaire, 10920, rue Rome, Montréal Nord, pour les objets suivants: Manufacturer et négocier des appareils de chauffage, des réseaux et contrôles de climatisation, sous le nom de « J & K Air Conditioning Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 40 actions ordinaires de 8100 chacune et 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera 35, rue Parc ouest, Dollard-des-Ormeaux, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 14e jour de septembre 1965.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.12409 4003-65 Les Joints International ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 13c jour de septembre 1965, constituant en corporation: Solly Roth, vendeur, Montréal, Israel H.Kaufman, avocat, Montréal, et Nelly Van Gyte, secrétaire, fille majeure, Brassard, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes d'équipement pour garnitures de pompes et articles connexes, sous le nom de « Les joints International ltée », avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 13e jour de septembre 1965.Le Sous-secrétaire de la province,' Raymond Douville.12409 4062-05 Kenniac Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première pari h- de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour de septembre 1905, constituant en corporation: Ross Trenhome Clarkson, 80, ave- Filion, St-Laurent, Jacques Bélisle, printer, J_> Jubinville, and Pierre Thomas, advocate, 250 Dea Êeores, the two latter of Laval, for the following purposes: To carry on business as printers, under lh, name of \"Imprimerie Normandie ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,500 common shares of 810 each and 250 preferred shares of 8100 each.The bead office of the company will he al Laval, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of September, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.12409 386 55 J & K Air (Conditioning Ltd.Notice is hereby given that under Part 1 of the Companies Act.letters patent, bearing date the 14th day of September, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Francois Payette, lawyer, 9020 Gouin Boulevard West, Paraguay, Jacques-L.Auger, lawyer, 8402 Drolet Street, Montreal, and Jean-Guy Lalande.notary, 10920 Rome Street, Montreal North, for Hie following purposes: To manufacture and deal in heating systems, air conditioning systems and controls, under flu name of \"J & K Air Conditioning Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 40 common shares of 8100 each and 3,000 preferred shares of 810 each.The bead office of the company will be at 35 West Park, Dollard-des-Ormeaux, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of September, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Provina .12409-o 4003-65 Les Joints International liée Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating-: Solly Both, salesman, Montreal.Israel H.Kafman, advocate, Montreal, and Nelly Van Gyte, secretary, spinster of the full age of majority, Brossard, for the following purposes: To deal in all kinds of pump packing equip ment and allied lines, under the name of 'Lei Joints International Itee\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common sliares of a par value of 810 each and 2,000 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of September, 1965.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.12409-0 4062-65 ken mac Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part 1 ol the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 1st day of September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor \"f the Province of Quebec, incorporating: Boss Trenholmç Clarkson, 80 Kenaston Avenue, i QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, I960, Vol.97, No.Li 5433 mu- Konuston, Mont Iloyal, Michael Kevin Smyth, 173, avenue Hrittany, Mont Iloyal, et David Terence Dingle, 501, avenue Lansdowne, \\\\c>(mount, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exarœr les affaires d'une compagnie de porte* feuille, sous le nom de « Kenmac Investments I.t.l., avec un capital total tic 1500,000, divisé un 800 actions ordinaires d'une valeur au pair ,i, >! chacune, 4,924 actions privilégiées catégorie 1 A » d'une valeur au pair de $100 chacune et 7.000 actions privilégiées catégorie « 11 d'une valeur au l>uir de SI chacune.I.c siège social de la compagnie sera à 4220, avenue Hingston, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour de septembre 1905.Le Soux-xecrêtaire de la province, Raymond Douvillk.12109 3005-05 I .au/.on Lumber Inc.Avis eel donné qu'en vertu de la première partie de la \\ju\\ des compagnies, il a été accorde, par le lieutenant-gouverneur de la province cie Québec, des lettres patentes, en date «lu I'm- jour de septembre 1965, constituant en corporation: Louis-Robert Ruel, comptable, 473, rue St-Joseph, .L-fidouard Ruel.gérant.\"Mi rue St-Joseph, ii Edgar Ruel.machiniste, 471.rue St-Joseph, ton- trois de Lan/ou.pour les objets suivants: Industrie et commerce «lu bois.sous le nom «le I.au/.on Lumber Inc.avec un capital total de 140,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et eu 200 actitms privilégiées «le $100 chacune.I.c siège social de la compagnie sera à Lauson, district judiciaire de Québec.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce L5e jour de septembre 1905.Le Soux-sccrltaire de la province.Raymond DouvTLLE.12409-0 4106-65 Laval Autorama ltf the company will be at 4226 Hingston Avenue, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the ollicc of the Provincial Secretary, this 1st day of September, 1005.Raymond Douvillk, Asxixtunt Secretary of the Province.12409-o 3005-05 I a11/on 1.1iniLit- Inc.Notice is hereby given that umler Part 1 of the Companies Act.letters patent, bearing date the loth day of September, 1065, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Louis-Robert Ruel, accountant, 173 St-Joseph St.J.-Êdouard Ruel, manager, 86 St-Joseph St.and Edgar Ruel.machinist, 171 St-Joseph St.all three of Lan/.on, f«>r the billowing purposes: The industry and business dealing in wooil.Upder the name of \"Luu/.on Lumber Inc.\", with a total capital slock of 810.000.divided into 200 common shares of 8100 each ami 200 preferred shares of 8100 each.The bead office of the company will be at Lauson, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of September, 1965.Raymond Doi villi.-Axxixtant Secretary of the Prorincc.12400 4105-05 Laval Autorama ltée Notice is hereby given that under Part I «>f the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of September.1905.have been isseud by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Dagcnais.merchant.847 Principale.S te-Do rot bee.Abraham Sinister, advocate, 5710 Wolsley.and Lawrence Glazcr, student.7920 Kingsley.the latter two of Côte-St-Luc, for the billowing purposes: To deal in new and used auto and motor vehicles of all kings, umler the name of \"Laval Autorama ltée\".with a total capital stock of 840,000.divided into 5,000 common shares of a par value of 81 each and 3.500 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at Ste-Dorothée.judicial district of Montreal.(liven at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of September.1905.Raymond Doivillk.Axxixtant Secretary of the Province.12409-o 4088-65 I « iktronic Sales Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of September, 1905, liavc been 5434 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre I96f>, 97' année, No L> Québec, des lettres patentes, en date du 14c jour de septembre 191)5, constituant en corporation: Albert Victor Stone, représentant de ventes, 11000, James Morrice, Abraham Gur-man, avocat, 5530, Côte-St-Luc, et Lawrence Diner, avocat, 40S5, avenue Harvard, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de pièces constituantes dans le domaine de l'électronique et de la mécanique, pièces d'autos et de machinerie pour l'industrie et le commerce, sous le nom de « Lek-tronic Sales Ltd.», avec un capital total de §40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Ia: siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 14e jour de septembre 1905.Le Sous-secrétaire de la province, .Raymond Douvillk.12409 4095-05 W.W.lx'vcsque inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quél>ee, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec, des lettres patentes, en date du 7e jour de septembre 1068, constituant en corporation: Normand I,evesque, commerçant, Solange (_'ôté, ménagère, ejxni.se séparée de biens dudit Normand Lcvesque, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de 585, Bowen, Magog, et Gérard Lussicr, courtier en assurances, 51, Deragon, Magog, pour les objets suivants: Faire le commerce de vêtements et de chaussures de toutes sortes, sous le nom de « W.W.Levesque inc.», avec un capital total de S40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Magog, district judiciaire de St-François.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 7e jour de septembre 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.12409-o 3969-65 Librairie M.C.inc.M.C.Stationery Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 15e jour de septembre 1065, constituant en corporation: Yvon Côté, marchand.133.rue Hoyer.Jcan-Guy Martin, marchand.194.rue Duffy.Annette Dandurand.secrétaire, fille majeure et usant de ses droits.4S Brodeur, tous trois de Dorion.et Pierre A.Lamarre, notaire.2.rue St-Michel.Yaudreuil, pour les objets suivants: Faire affaires comme libraires et papetiers, sous le nom de « Librairie M.C.inc.-M.C.Stationery Inc.».avec un capital total de 840,000, divisé en 15.000 actions ordinaires «le $1 chacune «\u2022t en 250 actions privilégiées «le 8100 chacune.I^e siège social de la compagnie sera à Dnrimi.«listrict judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province.OB 15e jour «le septembre 1905./ Le Sous-secrétaire de la prorinec, Raymond Douville.I2409-.) 3754-05 issued by the Lieutenant-Governor of the I'n,.vince of Quebec, incorporating: Albert Victor Stone, sales representative, 11000 James Mor-rice, Abraham Gurman, advocate, 5530 Cute-St-Luc, ami Lawrence Diner, advocate.; Igg Harvard Avenue, all three of Montreal, for the following purposes' To deal in electronic and mechanical components, auto parts and machinery for industry and commerce, under the name of \"Lektronic Sales Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and 300 preferred shares «>f $100 each.The hea«l office «>f the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1-4tli day of September, 1905.Raymond Douvillj .Assistant Secretary of the Province, 12400-«) 4095-65 Wê W.levesque inc.Notice is hereby given that umler Pari I ol the Quebec Companies Act, letters paient, bearing date the 7th day of September.I'\"'.a.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Normand Levesque, trader, Solange Côté, housewife, wife separate as to pr«>perty «>f said Normand Levesque, and duly authorized by him for the purposes by these presents, both of 585 Bowen, Magog, and Gérard Lussicr.insuace broker, ol Deragon, Magog, for the following purposes: To deal in clothing ami shoes of all kinds, under the name of \"VY.W.Levesque inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Magog, judicial district of St.Francis.Given at the office of the Provincial Secretary, this 7th day of September, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Provint -12409 3069 Librairie M.C.inc.M.C.Stationery Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day «»f September, 1005.have been issued by the lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, incorporating: Yvon Côté, merchant.133 Buyer St.Jean-Guy Martin, merchant.104 Dully St.Annette Dandurand, secretary, spinster of the fidl age of majority and in Use of her rights.48 Brodeur, all three «>f Horion, ami Pierre A.Lamarre, notary.2 St-Michel St.Yamlreuil.for the billowing purposes: To carry on business as librarians ami stationers, mule rthe name of \"Librairie M.C.inc.M.C.Stationery Inc.\", with a total capital stoek «)f 840,000, divided into 15.000 common shares of 81 each and 250 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be »l Dorion.judicial district of Montreal.Given at the office »>f the Provincial Secretary, this 15th day of September, 1065.raymond Doivillk.Assistant Secretary of the Province.1240») 3754-05 QUEBEC OFFICIAI, GAZETTE, October 16, I960, Vol.97, No.V I.in Huron Inc.\\\\is est donné qu'en vertu de la première partie de In Loi des compagnies, il b été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 15c jour de septembre 1005.constituant en corporation: Gisèle Magner, 6985, rue Sherbrooke, ouest, app.I |.Montreal, Nathalie L.llanspiker.5810, I oiiisbourg.St-Laurent, et Pleur-Ange Déearie, i71d boulevard Dorchester, ouest.Montréal, toutes trois secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: Exercer un commerce de manufacturiers «le peintures et vernis, sous le nom de « bin Huron lue.avec un capital total de 810.000, divisé ni 10 actions ordinaires d une valeur au pair de 1400 chacune et 00 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.I,e Biège social île la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné' au bureau du secrétaire de la province, ce 15e joui de septembre 1065.I.c Soits-sciri'taire de la province, Raymond Douville.12409 8908-65 Lilbogruphic Mt-Koyal Offset Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 24e jour d'août 1065, constituant en corporation: Philippe Dccelles, courtier eu assurances, 1, chemin Ellerdalc, app.0, Hampstead, Robert Langlois, comptable, 4S43, boulevard Hosemont, et André Pin, imprimeur, 0778, rue Georges-Baril, oss deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme imprimeurs, graveurs et lithographes, sous le nom de « Lithographie Mt-Royal Offset Inc.», avec un capital total de 810,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune.Ia- siège social de la compagnie sera 480, avenue Mont-Royal, est, chambre 20, Montréal, 'listrict judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 24e jour d'août 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou villi;.12409-0 3720-05 Les Loisirs de Ste-Clotilde Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 15e jour de septembre 1905, constituant en corporation sans capital-actions: Guy LalHtte, Gérard Clermont, maraîchers, Adrien Gamache, André Moïse, journaliers, Charles Pérou, fonctionnaire fédéral, Edward Dinningan, garagiste, Marcel Mo ut hi lier, comptable, et Denis Surpre-uant.jardinier, tous huit de Ste-Clotilde, pour les objets suivants: Établir et diriger un centre de loisirs, sous le nom de « Les Loisirs de Ste-Clotilde ».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de 8100,000.Le siège social de la corporation sera à Ste-Clotilde, district judiciaire de Beauharnois.5435 Liu Huron Inc.Notice is hereby given that umler l'art 1 of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of September, 1005, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gisèle Magner.0035 Sherbrooke Street West, Apt.14, Montreal.Nathalie L.Ilaiispikcr.6810 LouisboUTg, S(.Laurent, and r'lcur-Ange Décurie.1710 Dor- chester Boulevard West, Montreal, all three secretaries, spinsters, for the following purposes: To carry on the business of pain! and varnish manufacturers, under the name of \"Lin Huron Inc.\".with a total capital Stock Of * 10.000.divided into 10 common -hares of the par value of S100 each and 90 preferred sliares of the par value of s pli) each.The head ollicc of the company will be al Montreal, judicial district of Montreal.Given at the ollicc of the Provincial Secretary, this 15th day of September, 1965.Raymoni) Ivii.i.i;.Assistant Secretary of the Province.12409-0 3903-05 Lithographie M t-Boyal Offset Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of August, 1005, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporai ing: Philippe De-eel les, insurance broker, 1 Kllerdale Road, Apt.9, Hampstead.Robert Langlois.accountant, 4S43 Rosemout Blvd., and André Pin, printer, 9778 Georges-Baril St., the latter two of Montreal, for the following purposes: To act as printers, engravers and lithographers, under the name of \"Lithographie Mt-Royal Ofisct Inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 1,000 common shares of 810 each.The head office of the company will be at 4S0 Mount Royal Ave.East, Room 20, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of August, 1905.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.12409 3720-65 Les Loisirs de Ste-Clotilde Notice is hereby given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of September, 1005\", have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Guy Laffitte, Gérard Clermont, market-gardeners, Adrien Gamache, André Moïse, labourers, Charles Pérou, federal civil servant, Edward Dinningan, garageman, Marcel Bouthiller, accountant, and Denis Surprenant, gardener, all eight of Ste-Clotilde, for the following purposes: To establish and direct a recreational center, under the name of \"Les Loisirs de Ste-Clotilde\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire ami hold is to be limited, is 8100,000.The head office of the corporation will be at Ste-Clotilde, judicial district of Beauharnois. 543») GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre 1965, 97e année, No & Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 15c jour de septembre 1965.Le Sous-secrétaire Je la province, Raymond Douvillk.12409-o 407645 Lucerjam Inc.Avis «-,1 donné «pieu vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies, il a été ace«>nlé, par h- lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, «-n date «lu lue jour *.Kensington.Montréal.Robert Learmonl Jamieson, avocat et conseil en I,«»i «le la reine, 15.Westwood Drive.Pointe-Claire et Klhcl Davies.secrétaire, épouse divorcee «le Noël (îwyiiuc Davies.2122.rue Dépalic, St-Laurent.pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, construction et placements, sous le nom «le Lucerjam Inc.avec un capital total «le SI.000.divise en 1.000 jutions ordinaires de 81 chacune.Ia' siège social «le la compagnie sera 1010.rue Ste-Catherine «)u«-st.chambre 1020.Montival, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire \u2022 !«\u2022 la province, «\u2022«¦ lue jour de septembre 1965.Le Sous-seerétairc Je la province, Raymond Doivillk.12409 4015-66 Marché R.Mayrand ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a ét«; accord»'-, par lf August, 1905.have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 10, I960, Vol.97, No.J,.i province de Quebec, «les lettres patentes, en date du 30e jour d'août 1906, constituant en corpora- liuii: Harvey Crestohl, avocat, 158, avenue hockhart.Mont Royal, Avium Cohen, avocat.1400, 3c Hue, Laval, et Heverlec Boldovitch, secrétaire, 611e majeure et usant dé BBS ilroits, 2201, avenue Maplcwootl.Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie «l'iin-meiihlcs et «le construction, sous le nom «le « Oris tue.avec un capital total «le $40,000, divisé en 1.ill HI actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donne an bureau «lu secretaire carry on the business of a real estate and construction company, umler tin- mum- of \"Oris Inc.\".with a total' capital stock of 840,000, divided iotfl 4.000 common shares of $10 each.The bead office f the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(îiven at 111«- office of the Provincial Secretary, this 30th day of August.1965.Raymond Douvillk, Assistant Seeretarji of the Province.I2409-o 3852-65 P.P.Electric Inc.Notice is hereby given that under Part 1 «»f the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 7th day of September, 1965, have been issued by tin- Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: lluguctte Corbeii, secretary, fill** majeure, 7!) (iuy St., Sainte-Rosalie, Léon Nichols, advocate, 1555 Girouard, Denis Robert, probationer, 1015 Bourassa, and Jacques Gauthier, «\u2022hartereil accountant, 2285 Girouard, the three latter of St.Hyacinthe, for the following purposes: To carry on business as electrical contractors, under the name of \"P.P.Electric Inc.\", with a total capital stock of 8100.000.divided into 000 common shares of 8100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head oilice of the company will be at Si.Hyacinthe, judicial «listrict of St.Hyacinthe.Given at the office «>f the Provincial Secretary, this 7th «lay of September.1005.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.12400 3007-05 Palmers Plumbing Supply (Quebec) Limited La Compagnie de plomberie Palmers (Québec) limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Raymond Crevier, lawyer, Clifford George Meek, accountant, Colin Richard Chisholm, clerk, all three of Montreal, Ernest William Mockridge, manager, S^-Lambert, and Theodore William Martinson, accountant, Westmount, for the following purposes: To carry on the business of plumbing, heating, electricity and ventilation contractors, under the name of \"Palmers Plumbing Supply (Quebec) Limited \u2014 La Compagnie de ploral)erie Palmers (Québec) limitée\", with a total capital stock of S1,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of September, 1965.Raymond Douville, I Assistant Secretary of the Province.12409-o 3866-65 5440 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Hi octobre 1965, 97' année, No ig Holland Papillon lin.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a «'\u2022té accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Quebec, «les lettres patentes, en date «lu 30c jour d'août 1005, constituant en corporation: Louis IL Rohrlick, avocat et conseil en Loi de la reine, 4300, Western, West mount, Benjamin J.Cîrcenberg, av«>cat, -1211, Grand Boulevard, Stephen Goldschleger, avocat, 1000 McGregor, et Thérèse Perreault, secrétaire, lillc majeure, 10430, André-.lobin, app.3, ces trois dernières de Montival, pour les objets suivants: Manufacturer des carpettes, œuvre-planchers et autres articles pour l'embellissement du foyer, et en faire le c«)inmer«'«', s«>us le nom «le « Rolland Papillon Inc.', avec un capital total «le 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de 81 chacune et 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le .Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 30e jour d'août 1966.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.12400 3863-66 P.A.Pelletier ltée Avis «-st donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies, il a été accordé, par le liculcnaut-gouvcrucur de la province «le Québec, des lettres patentes, en «late «lu 13e jour «le septembre 1965, constituant «m corporation: Pierre A.Pelletier, industriel et restaurateur, Augustin Pelletier, gérant, comptable et administrateur, cl Roland Pelletier, commis répartiteur, tous trois «!«\u2022 La Malbaie, pour les objets suivants: Pair»' !«\u2022 commerce «le produits pétroliers et «!«\u2022 tous h's produits dérivés «lu pétrole, sous le mun «le « P.A.Pelletier ltuverncur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en date «lu 13e jour de septembre 1965, const it liant en corporation: Michel Côté, avocat.Marie Duhamel, ménagère, épouse séparée «le biens dudit Michel Côté, tout deux «le 805, rue Royale, et Claudette MadLeod, secrétaire.épOUSC séparée de biens d'Fnnio Sli-var, 0X2, rue Frontenac*, tous trois r the following purposes: To manufacture and deal in rugs, floor covering ami other home improvement, under the name of \"Rolland Papillon Inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 10,000 common shares of $1 each ami 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will !>¦\u2022 ai Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the oflice of the Provincial Secretary, this 30th day «>f August, 1005.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Provinn.12400-o 8853-65 P.A.Pelletier ltée Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of September, 1005.have been issued by the Lieiiteuaut-(îovernor of the Province of Quebec, incorporating: Pierre A.Pelletier, industrialist ami restaurant keeper.Augustin Pelletier, manager, accountant and administrator, and Roland Pelletier, clerk, distributor, all three of La Malbaie.for the following purposes: To deal in petroleum products ami all products derived from petroleum, umler the name of \"P.A.Pelletier ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company will be al Malbaie River, judicial «listrict of Saguenay.(îiven at the ollicc of the Provincial Secretary, this 13th day of September, 1965.Raymon d Douville, Assistant Secretary of the Province.12409 4059-65 Pétrole Quevillon limitée Quevillon Petroleum Limited N«>tice is hereby given that under Part I \"i the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of September, 1005.have been issued by the Lieutenant-(îovernor of the Province of Quebec, incorporating: Michel Cote, advocate, Marie Duhamel, housewife, wife separate as to property of the said Michel Côté, bol h of 805 Royale St.and Claudette MacLeod, secretary, wife separate as to property of Ennio Sttvar, 682 Frontenac- St.all three of Malartic.for the following purposes: To carry on business dealing in petroleum, \"il and gasoline, under the name of \"Pétrole Que -villon limitée Quevillon Petroleum Limited' with a total capital stock of 840,000.divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office t>f the company will be al 300 Fournière Ave.Malartic.judicial district «)f Abitibi. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 10, I960, Vol.97, No.i£ Donné au bureau du secrétaire de la province, 13e jour de septembre 1065.I.c Sons-xccr/taire de la province, Raymond Douville.12400*0 3007-65 IMinTinnii\", des Huit inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Été accordé, par l'administrateur du gouverne* nient de la province de Québec, des lettres patentes, en «late «lu 2e jour «le juillet 1065, constituant en corporation: Jacques R.Roy, avocat, 174.Desmarteaux, La val-«les-Rapides.Raymond Brosseau, comptable agréé, 6227, Viau, et Francois (îtxllmnt, avocat, 4875, Walkley, ces deux derniers «!«\u2022 Montréal, pour les objets suivants: Paire affaires comme compagnie «le finance* ment et de plaef the Province of Quebec, incorporating : JacquesR.Roy, lawyer.174 Desmarteaux, Laval-des-Kapides, Raymond Brosseau, chartered ac* countant, 0227 Viau, and François Godbout, lawyer, 4875 Walkley, the latter two of Montreal, f«ir the following purposes: To carry on business as a finance and investment company, under the name ec Companies Act, letters ( patent, bearing date the 7 th day of September, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: G.Harold Pickel, 47 Arlington, Westmount, Guy E.Boisvert, 4970 Glencairn, Montreal, and Claude Boisvert, 1505 Moore, Laval, all three advocates, for the following purposes: To deal in motor vehicles and to carry on business as garage keepers, under the name of \"Michel Poirier automobile ltée\", with a total 5442 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 10 octobre 1005, 07' année, No capital total de 1100,000, divisé en 2,500 actions ordinaires «le 810 chacune et en 750 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Juliette, \u2022 listrict judiciaire de Joliette.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 7e jour de septembre 1965.Le Sons-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.12409-o 3078-65 Polyclinique de .Montréal inc.Montreal Polyclinic Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été aeconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 7c jour de Septembre 1965, constituant en corporation: Dr Paul A.Gagnon, 3221, Place Hélène-Roullé, Dr Odilon Raymond, 5005, Place d'Aiguillon, Dr Rercbmans Laforest, 2325, Nico-las-Perrot, Dr André Proulx, 15, des Érables, tous quatre de Montreal, et Jacques Xoiseux, 27, boulevard Chambord, Lorraine, tous cinq médecins, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeuble, sous le nom de « Polyclinique de Montréal inc.- Montreal Polyclinic Inc.», avec un capital total de 8500,000 divisé en 1,000 actions classe « A » d'une valeur nominale de 80.10 chacune, 00,000 actions classe « B » d'une valeur nominale de 80.10 chacune et.en 400,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 7e jour de septembre 1005.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.12400-e 3997-05 Les Produits forestiers L'Ascension ltée L'Ascention Forest Products Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a été accorde, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date «lu l(k' jour de septembre 1005, constituant en corporation: Bernard Bock, industriel, 1915.Dumfries, Léonard Barrett, industriel.102, avenue .Melbourne, Rodolphe Paré, avocat, 385, avenue Barton, tous trois de .Mont-Royal, et Rose-Aimée Pou-drette, secrétaire, fille majeure, 2101, Sherbrooke, est, Montréal, pour les objets suivants: Industrie et commerce du bois, sous le nom de « Les Produits forestiers L'Ascension ltée \u2014¦ L'Ascension Forest Products Ltd., avec un capital total de 8200,000, divisé en 2.000 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à .Montréal, «listrict judiciaire «le .Montival.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 10e jour de septembre 1905.Le Sous-secrétaire de lu province, Raymond Douvillk.12409-c 4030-05 Les Ramoneurs du Sud inc.Avis est donné qu'en vertu -le la première partie de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patent*'*, en «late du 14e jour de septembre 1905, constituant en corporation: Marcel Landry, avocat, André Meek, ajusteur d'assuraïu'cs, tous deux «le Montrée Pr-'-Vort, capital stock of $100,000, divided into 2,500 common shares of 810 each and 750 preferred shares of 8100 each.The head oiliee of the company will be at Joliette, judicial district of Joliette.(liven at the office of the Provincial Secretary, this 7th day of September, 1965.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.12409 8978-65 Polyclinique de Montréal inc.Montreal Polyclinic Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing dale the 7th day of September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Dr.Paul A.Gagnon, 3221 Place Hélène-Boullé, Dr.Odilon itaymond, 5005 Place «l'Aiguillon, Dr.Iler-clunans Luforest, 2325 Nicolas-l'errol, Dr.André Proulx, 45 «les Érables, all four of Montreal, and Jacques Noiseux, 27 Chambord Boulevard.Lorraine, all five doctors, for the following purposes : To deal in real estate, under the name of \"Polyclinique «le Montreal inc.- Montreal Polyclinic Inc.\", with a total capital stock of 8500,000.divided into 1,000 class \"A\" shares of a nominal value of 80.10 each, 09,000 class \"B\" shares of a nominal valueof80.10 each and into400,000pre-ferrcd shares of a nominal value of 81 each.The head oflice of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.(iiven at the oflice of the Provincial Secretary.this 7th day of September, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.12400 t 3997-65 Les Produits forestiers L'Ascension ltée L'Ascention Forest Products Ltd.Notice is hereby given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, hearing date the 16th day of September, 1905, have been i-.icil by the Lieutenant-Governor «»f the Province of Quebec, incorporating: Bernard Bock, industrialist, 1015 Dumfries.Léonard Barrett, industrialist, 102 Melbourne' Ave,.Rodolphe Paré, advocate^ 385.Barton Ave., all three of Moiint-Royal.and Rose-Aimée Poudrette, secretary, fille majeure, 2104 Sherbrooke St.East, Montreal, for the following purposes: The industry and business dealing in lumber, uiuler the name of \"Les Pnxluits forestiers L'Ascension ltée \u2014 L'Ascension Forest Produits Ltd.\", with a total capital stock of 1200,000, divided into 2,000 common shares of 8100 each The head office of the company will be al Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the oflice of the Provincial Secretary, this 10th day of September, 1905.Raymond Dou villi:.Assistant Secretary of the Province.12409 4030-65 Les Ramoneurs du Sud inc.Notice is hereby given that under Part 1 ol the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of September, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Marcel Landry, advocate, André Meek, insurance adjuster, both «>f Montrée Pré-Vert, Bcloeil, and 5443 Ueloeil, «'t Claire Parent, secret aire, fille majeure, jJJs.Sherbrooke, eat, -Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie du ramonage des cheminées, son- le nom «le « Les Ramoneurs du Sud inc.¦>, avec un capital total «le 820,000.divisé en 200 actions oramajrei «le $10 chacune et en 180 a.lions privilégiées «!«\u2022 §100 chacune.be siege social «le la compagnie sera à Brassard, district judiciaire do Montréal.Donné au bureau du secrétaire «h1 la province, œ i b- jour «le septembre 1966.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.12409-0 -1101-05 Quebec bead Refiners Inc.Avis «-st donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a it/ accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late ilu 23e jour «l'août 1905, constituant en corporations Edward Samuel Berger, Julius Rosen- liluin.tous deux avocats.Susan Ramer, secrétaire, épouse séparée «le biens «le Roy Ramer, el Micheline Réliveau.commis, fille majeure, tous quatre «le 159, rue Craig, ouest, Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce «le raffineurs et fondeurs (l«- tous genres iège social «le la coin pagine sera 109.( otc-dc-la-Montagne.Québec, «listrict judiciaire 'le Québec.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, \u2022 i- 2e jour d'août 1905.Le Sons-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.I2409-o 3483-05 Regis Antiquaire inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 14e jour «le septembre 1905, constituant en corporation: Régime Lheritier, ménagère, épouse contractuelle-Btent séparée de biens de Jean-Noël Lavoie, 4180, Claire Parent, secretary, Aile majeure, 222s Sherbrooke St.Kast.Montreal, for the following purposes: To carry on the industry of chimney-sweeping, umler the name of \"Les Ramoneurs «lu Sud inc.\".with a total capital str the following purposes: To deal in furniture ami oflice accessories, uiuler the name of \"Rapid Data (Quebec) Inc.\".with a total capital stock «>f 850.000.divided into 500 common shares of 810 each and into 450 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 109 C6te-de-la-Montagne, Quebec, judicial «listrict of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day «>f August.1905.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.12409 34X3-05 Regis Antiquaire inc.Notice is hereby given that uiuler Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of September, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Régine Lheritier, housewife, wife contractually separate as to property of Jean-Noël Lavoie, 4180, 1st Street, Laval, GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre I960, 97' année.No 1,2 5141 Ire Bue, Laval.Nicole Tardif, secrétaire, fille majeure, 6776, si Denis, .Montréal, «'t Monique Bergeron, secretaire, 611e majeure, 3380, avenue -Maplewood, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme antiquaires, SOUS le nom de « Regis Antiquaire inc.», avec un capital total de 110,000, divisé en 100 actions ordinaires de 810(1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, Ce 14e jour de septembre 1965.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.12409-o 399846 Revêtements D.S.inc.D.S.Coatings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 7e jour de septembre 1905, constituant en corporation: Gaston Founder, vendeur, 27, rue Paquin, Madeleine Founder, ménagère, épouse de Noël Dansereau, 57S, rue Clierrier, tous deux de St-Raphaël-ded'lle-Bizard, et Laurette Proulx, ménagère, épouse de Rosaire Asselin, 170, Place Laframboise.app.R.Ste-Geneviève, pour les objets suivants: Faire le commerce «le tous genres de revêtements, d'équipement et.de matériaux de construction, sous le nom de * Revêtements D.s.inc.\u2014 1).S.Coatings Inc., avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint -Raphaël-de-l'Ile-Bi/.ard, «listrict judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 7e jour «le septembre 1965.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.12400-o 4024-05 Rockland Quarries Inc.Avis «-st donné qu'en vertu de la première partie «!«\u2022 la Loi «les compagnies de Québec, il a été aeconlé.par le lieutcnant-gouv«Tneur «le la province de Québec, des lettre.-, patentes, en date du 14«' jour de juin 1005.constituant en corporation: Nairn Bar/.el.architecte, Violet Meir, ménagère, épouse séparée de biens dudit Nairn Barzel, tous deux de 3140.avenue Maplewood, Montréal, Gustav Dell, manufacturier de pierre, et Irene (i.Totll, ménagère, épouse «ludit Gustav Deli.ces deux derniers de 3112.rue Esther, Laval, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'exploitation «l'une carrière dans Franklin Centre.SOUS le nt>m «le « Rockland Quarries Inc.», avec un capital total «le 820,000, divisé en 50 actions ordinaires «le 8100 chacune et 1.500 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montival.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 14e jour de juin 1965, Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.12400 2756-65 Nicole Tardif, secretary, fille majeure, 6778 St-Denis, Montreal, and Monique Bergeron, secretary, fille majeure, 3380 Maplewood Avenue, Montreal, f«>r the following purposes: To carry on business as antiquarians, under the name of \"Regis Antiquaire inc.\", with a total capital stock of 810,000.divided Into 100 common shares of 8100 each.The head office «)f the company will be al Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of .September, 1005.Raymond Douvilli.Assistant Secretary of the Province.12400 3998135 Revêtements D.S.inc.D.S.Coatings Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters paient, bearing «late the 7th day of September, 1965, have been issued by the Liculenant-Goverui p of the Province of Quebec, incorporating: Gaston Founder, salesman, 27 Paquin Street, Madeleine Founder, housewife, wife of Noël Dansereau, 578 Clierrier Street, both «>f Sl-Raphael-tlel'Ile-Bizanl, and Laurette Proulx, housewife, wife of Rosaire Asselin, 470 Place Laframboise, apt.B, Stc-Geneviève, for the following purposes: To deal in all kinds «>f coatings, equipment and construction material, under the name of \"Revêtements D.S.inc.\u2014 D.S.Coatings Inc.\".with a total capital stock of $40,030, divided into 100 common shares of $100 each.The head oflice of the company will be al Saiut-Raphaël-de-rile-Bi/.ar«l, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 7th day of September, 1005.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.12400 402 5-05 Rockland Quarries Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day «>f dune.1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, incorporating: Nairn Barzel, architect.Violet Meir, housewife, wife séparai « as to property «>f the said Nairn Barzel, both of 31 W Maplewood Avenue, Montreal.Gustav Deli, stone manufacturer, and Irene (î.Toth, housewife, wife of the said Gustave Deli, the latter tWO of 3112 Esther Street.Laval, for the following purposes: To carry on the business of operating a quarry in Franklin Centre, under the name of \"Rockland Quarries Inc.\".with a total capital stock of 820.000, divided into 50 common share- of 8100 each and 1.500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will ve al Montreal, judicial «listrict of Montreal.(îiven at.the oflice of the Provincial Secretary, this 14th day «»f dune.1005.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Proriuee 12409m 2756-65 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, 1965, Vol.97, No.J0 Salon de coiffure Tropicul inc.Vvi» esl donné qu'en vertu de lu première partie de In Loi «les compagnies «le Quebec, il a ICCOrdé, pur le lieutenant -gouverneur «!«\u2022 la ptovincc \\vlins.commerçant, 282, Me loche, CCS deux derniers «!«\u2022 St-Laurent, pour les objets suivants: Exploiter un OU «les salons «le coilfure, SOUS le nom «le « Salon de coiH'uiv Tropical inc.avec m.capital total de 140,000, divisé en 2.000 actions ordinaires de 810 chacune el en 200 actions privilèges f the Province of Quebec, incorporating: Marthe Leblanc, hairdresser, wife separate as t«> bed and board of Joseph Lafleur.4455 Coolbrook, apt.17.Montreal.April Rowlins.hairdresser, wife of Geoffrey Gibson, 1760 Décarie, apt.20, and William A.Rowlins.merchant, 282 Melo-che, the latter two «)f St-Laurent.for the following purposes: To operate one or several tuurdressing salons.under the name of \"Salon de coiH'ure Tropical inc.\", with a total capital stock of 840.000.«li-vided into 2,000 common shares of 810 each and 200 preferred «mares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict «>f Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 7th day of September, 1966.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.12409 3981-65 Salon Vogue Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 2nd day of September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Murray IL Spiegel.Harvey M.Cooperstone, both advocates, of 1010 St.Catherine Street West.Montreal, Nicole Graf, secretary, spinster, 43IS Boyee, Montreal, and Doris Cha/.onofF, secretary, spinster, 1412 Elizabeth, Laval, for the following purposes: To carry on the business of a beauty salon, umler the name of \"Salon Vogue Ltd.\".with a total capital stock of 840.000.divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of 810 each.The bead office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of .Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day of September, 1905.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.12409-«.3930-65 Sandi's Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 3r«l day of September, 1905.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Lewis D.Batshaw, attorney.4804 Côte-des-Neiges, .Montreal, Frederick L.Solomon, attorney, 4685 Westmount Avenue.Westmount, Henry S.Pesncr, chartered accountant.4721 Dornal Avenue.Montreal, ami Emma Giagnacovo, secretary, spinster, 4676 Alexander.Pierrefonds.for the following purposes: To «leal in clothing ami wearing apparel, uiuler the name of \"Saiuli's Inc.\", with a total capital stock of 840,000.divided into 1.000 common shares of 810 each and 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Pointe-Claire, judicial «listrict of Montreal. 5416 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre I960, 97' année, No L2 Donne un bureau du see refaire de la province, ce 8e jour de septembre 1905.Le Sous-secrétaire de lu proeince, Raymond Douvillk.12400 3648-66 Sani Industies Ltd.Avis est donné qu'en vertu tic la première partie de la Ix>i des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, eu date du 13e jour de septembre 1965, constituant en corjH)-ration: Max S.Kaufman, avocat et conseil en loi de la reine, 574, avenue Clarcmont, West-mount.J.Boy Hoffman, avocat et conseil en loi de la reine, 4918, avenue Mayfair, et Oscar Respite, avocat, 4945, avenue (Jleneairn, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer des produits de plastique vinyl et en faire le commerce, sous le nom de « Sani Industries Ltd.», avec un capital total de 8100,000, divisé en 500 actions ordinaires de 8J00 chacune et 500 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de .Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 13e jour de septembre 1905.Le Sous-secrétaire de la province, raymond Douville.12409 4056-65 Ia>» Savons Black Lake limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 19e jour d'août 1905, constituant en corporation: Lionel Angers, marchand, Agathe Du-l)ois, ménagère, épouse commune en biens dudit Lionel Angers, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux «le 424, rue Goulet, Black Lake, et Fernande Cyr, ménagère, épouse séparée de biens de Jean-Luc Dubois, 374, rue Goulet, Black Lake, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de produits chimiques, de savons, engrais, peintures, vernis et huiles de toutes sortes, sous le nom de « Les Savons Black Lake limitée », avec un capital total de 818.000, divisé en 150 actions ordinaires de 8100 chacune et en 30 actions privilégias de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 424, rue Goulet, Black Lake, district judiciaire de Mégan-tic.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 19e jour d'août 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.12409-o 3000-05 Maurice Seguin inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 7e jour de septembre 1905.constituant en corporation: Maurice Séguin, commerçant, 2095, Clifton.Montréal.-Mariette Rancourt.secrétaire, fille majeure, et Guy Pépin, avocat, ces deux derniers «le 200.rue St-Jacques, ouest.Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un service d'adressage, de polycopies, «le pliage, «le mise sous enveloppes et, en général, un service complet de mise à la poste, sous le Given at the «>f!i«-«' of the Provincial Secretary, this 3rd day of September, 1965.Raymon q Doi \\ ii.i.i .Assistant Secretary of the Prorinci I2409-o 39484\") Suni IndtisticK Ltd.Notice is hereby given that under Pari ! of the Companies Act, letters patent, bearing late the 13th day of September, 1905, have been Eased by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Max S.Kaufman, advocate and Queen's Counsel, 574 Clare-inout Avenue, Westmount, .1.Roy Hoffman, advocate ami Queen's Counsel, 4918 Mayl'air Avenue, and Oscar Respitz, advocate, 1945 Glencairn Avenue, the latter two of Montreal, for the folhnving purposes: To manufacture and deal in vinyl plastic products, umler the name of \"Sani Industries Ltd.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 500 common shares of 8100 each and 500 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will I at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Seer- larv.this 13th day of September, 1965.Raymond Dou villi.Assistant Secretary of the Province, 1240!i-«) 405545 Lea Savons Black Lake limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of August, 1005, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Lionel Angers, merchant, Agathe Dubois, housewife, wife common as to property of said Lionel Angers, ami duly authorized by him for the presents, both of 424 Goulet Street, Black Lake, and Fernande Cyr, housewife, wife separate as to property of Jean-Luc Dubois, 374 Goulet Street, Black Lake, for the following purposes: To manufacture and deal in chemical products, soaps, fertilizer, paints, varnishes and oil- of all kinds, umler the name of \"Les Savons Black Lake limitée\", with a total capital stock of 818,000, divided into 150 common share- of 8100 each and into 30 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 424 Goulet Street, Black Lake, judicial district of Mcgantic.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of August, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.12409 3660-65 Maurice Seguin inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 7th day «»f September.1965, have been issueil by the Lieutenant -Governor of the Province of Quebec, incorporating: Maurice Seguin, trader, 2095.Clifton, Montreal.Mariette Rancourt, secretary, fille majeure, and Guy Pepin, advocate, the two latter of 200 St.James St.West, Montreal, for the following purposes: To operate an adressing.p«dycopying, folding, cnvclopping service, and, in general, a complete mailing service, umler the name «>f \"Maurice QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 10, J90Ô, Vol.97, No.Li 5447 ikmi iiV « Maurice Seguin inc., avec un ciij)il;il i, .\\ de 140,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de s nu chacune.Le siège social de Is compagnie sera à Montréal, i i judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, , c 7e jour de septembre 1005.Le Sous-secrétaire f the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.(iiven at the office «»f the Provincial Secretary, this 7th day of September, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Produce.1210!» 4029-65 Service de lessiveuse Ste-Foy inc.Notice is hereby given that under Part I of tin- Companies Act.letters patent, bearing 'late the bub day of September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of tin- Province of Quebec, i incorporating: Gilles St-Hilaire.advo- cate, 34 «l«' la Fabrique, Quebec, Colette Samson, secretary, Bile majeure, 3403.Place Trilanon.Ste-Foy, and Narcisse Proubx, clerk.77 St-Louis St., Quebec, for the following purposes* To carry on business as electricians, under the name of \"Service r«- 1966, «-«instituant «-n corporation: Chin Toy, gar«;on «!«\u2022 table, 5237, avenue du l'are.Montréal.Hark .long Lcm, gérant.4433.avenue H«*»tel «h- Ville, Montréal, «-t (ic«>rgc Ia'v.ivstauratcur.1281, Lakeshore Drive.Dorval.pour les objets suivants: Exploiter un restaurant et les services «l'appro-visionnement «le nourriture, sous le nom «le « Sun Luck Restaurant Ltd.avec un capital total de $40,000, «livisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $100 chacune.Le siège social «h- la Compagnie sera à .Montival.«listrict judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, f $40.000.divided into 1,000 ««,,.,-mon shares of $10 each and .500 preferred duo.\u2022 «>f «100 each.The head ollicc of the company will be at Fairview Shopping Centre, Pomte-Claire, ju«li.cial district of Montreal (iiven at the office «>f the Provincial Secretary this 2nd day of September, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Sccretari, of the Provint, 12409-e 3932-65 Sun Luck Restaurant Ltd.Notice is hereby given that under Part I al the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th f September, l!»05.have been issued by the Lieutenant-(iovcrnor of the Province of Quebec, incorporating : Chin Toy, waiter.5237 Park Avenue, Montreal.Dark Jong Lent, manager.4433 City Hall Avenue.Montreal, ami George Lee, restaurateur, 1281 Lakes!iore Drive.Dorval.for I be following purposes: To operate a restaurant ami food catering services, under the name «>f \"Sun Luck Restaurant Ltd.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of S100 each.The head office of the company will lx al Montreal, judicial «listrict of Montreal.(iiven at the office «>f the Provincial Secretary, this 13th day of September, 1965.Raymond I toi villi .Assistant Secretary of the Provint, I240!»-o 4065-65 Sunnydalc Cleaners Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of Septemlier.1005.have b«-«-ii issued by the Lieutenant-(iovcrnor of the Province of Quelm*c.incorporating: lien Zillier.merchant.4895 De La Pelt rie.H y man Fogel, merchant, 4285 De La Pcltrie, and Abraham (oilman, advocate, 5530 Cote-St-Luc, all tine, ol Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general dyeing and cleaning, under the name «if \"Sunnydah- Cleaners Inc.\".with ¦ total capital stock of $40,000, divided into 10.000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares «>f $1 each.The head office «>f the company will lx- at 3606, Montée «les Sources.D«dlariLdcs-()rin«-a'!\\.judicial district «if M«intreal.(iiven at the office «>f the Provincial Secretary, this 14th day of September.1965.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Provina 12409-e 1106-65 Top Investment Ltd.Notice is hereby given that uiuler Part I f the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 27th day of August, 1965, have been issued by the Lieutenant-(îovernor properl of Abe Budovitch, 7401 Kingley Uoa«l, all three «if Montréal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, 196',, Vol.97, No.1$ 5449 Exercer lei affaires d'une compagnie de place* ments, loui le nom «le « Top Investment Ltd.», uq capital total «le 140,000, «livisé «m 1,000 actions ordinaires de 110 chacune «-t 800 actions prh il giées de 1100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à .Montréal, district judiciaire de -Montréal.Donné au bureau du sec rétaire de la province, , i 27e jour d'août 1966.I.c Sous-secrétaire de la prurtuce.Raymond Douville.12400 3830-66 I Wall Schools l'or Israël ivis esl donné qu'en vertu «le la troisième partie de la Loi «les compagnies, il a été accordé, par !«\u2022 lieutenant-gouverneur de la province ilieinont.MeyerSchecter, administrateur.953, hnnlop.Outremont.Moees Salsberg, administrateur, 5740, Déom, Montréal, Israël Gcpner, agent d'immeubles, 5831, Plantagenet, Montréal.T/udyk Mendcleorn, fourreur.2072.Brighton.Montréal, «d Moishe iVusabaum, entrepreneur, 78, llillerest Drive.Toronto, province «l'Ontario, pour les objets suivants: Paboriser, entreprendre et poursuivre, soutenir, stimuler et aider l'éducation religieuae qui contribue à la perpétuation des coutumes, «les fêtes, du langage, «lu rite et «le la religiim hébraïques, sous le nom «le « Torah Schools for Israël >>.Le montant auquel est limitée la valeur «le la propriété immobilière que la corporation peut posséder OU détenir est de 8100,000.Le siège social «le la corporation sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montival.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, \u2022 9e jour de septembre 1965.I.c Sous-secrétaire de la produce, Raymond Douville.09 4067-05 F.Tourigny construction limitée Vvis est donné qu'en vertu de la première lie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la rince de Québec, «les lettres patentes, en date 16e jour d'août 1905, constituant en corpo- ¦ on; Michel Côté, avocat, 805, rue Royale, Claudette Mac Leod, secrétaire, épouse séparée \"\u2022 biens d'Ennio Slivar, 0S2, rue Frontenac, et NIarie Duhamel, ménagère, épouse séparée «le biens dudit Michel Côté, 805.rue Royale, tous ; ss de Malartic, pour les objets suivants: aire affaires comme entrepreneurs en construction, sous le nom de « F.Tourigny const ruc-lion limitée \\ avec un capital total «le 840,000, divisé «-n 4,000 actions ordinaires «le §10 chacune.e siège social de la compagnie scia 401.Har-l'i 'ha, Malartic, district judiciaire d'Abitibi.To carry on il\"' business of an investment company, under the name f \"Top Investment Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of §10 each ami .'100 preferred shares f 6100 each.The head office f the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the ollicc of the Provincial Secretary, this 27th day of August, I«)\u2022;;>.Raymond Douvilu .Assistant Secretary of the 1'rorincc.12409-0 3830-05 Torah Schools for Israël Notice is hereby given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 0th day «>f September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor f the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Reverend Pinchus Dirschprung, rabbi.230 Querbes Street, Outremont, Reverend Mendell Lewittes, rabbi.1042.Clinton Montreal.Reverend ('haini N.Denburg, rabbi, 4732 Bouchet, Montreal, Dr.Henry Biberfeld, doctor, 660 McEachran, Outremont, Jacob L Kraminer, executive, 124 Aberdeen, Westmount, -Max Garmaise, notary.0040 Wilderton Avenue.Montreal, Louis Drasin, notary.612 St.fames Street West, Montreal, Manfred Pfeiffer, (bartered accountant, 1043, Pratt.Outremont, Meyer Schecter, executive, 053 Dunlop.Outremont, Moses Salsberg, executive, 5740 Déom, Montreal.Israël Gepner, realtor, 5831 Plantagenet, Montreal.T/udyk Mendekorn, furrier.2972 Brighton, Montreal, and Moishe Nussbaum, contractor, 78 llillerest Drive.Toronto.Province «'f Ontario, for the following purposes: To promote, undertake and pursue, support, favour and aid religious education conducive to the perpetuation of the Hebrew religion, ritual, language, festivals ami customs, under the name of \"Torah Schools for Israël\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may own or hold is to be limited, is 8100,000.The head ollicc of the corporation will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 9th day «>f September, 1905.Raymond Dotvn.i.i., Assistant Secretary of the Produce.12409-o 1087-65 F.Tourigny construction limitée Notice is hereby given that uiuler Part I «)f the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the Kith «lay of August, 1905.have been issued by the Lieutenant -Governor «>f the Province of Quebec, incorporating: Michel Côté, advocate, 805 Royale St.Claudette Mac Leod.secretary, wife separate as to property of Kiinii» Slivar.0X2 Frontenac St., ami .Marie Duhamel, housewife, wife separate as to property of the said Michel Côté, 805 Royale St.all three of -Malartic, for the following purposes: To carry on business as building contractors, under the name t>f \"F.Tourigny construction limitée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4.000 common shares of §10 each.The head office «»f the company will lie al 401 Harricana.Malartic, judicial district of Abitibi. 5450 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre 1965, 97' année, So 42 Donné au bureau du secretaire «h* b province, l ici of Chaieoutimi.(Jiven at the ollicc «»f the Provincial Secretary, this 1st day of September, 1965.Raymond Dot vii.i.i.Assistant Secretary of the Provina I24O0 3909-65 I.« - Transports communautaires ltée Community Transports Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of September, 1965, have been issued by the Lieuteuant-(iovcrnor of the Province of Quebec, incorporating: Luc Geoffroy, advocate, 821 Brian*! Blvd.Chanibly.Denyse Cadieux, receptionist, fille majeure.410 Prieur St.East, Montreal, and Jeannette Brodeur, secretary, spinster «>f the full age of majority, 3450 Duro-cher.Apt.31.Montreal, f«»r the following purposes: To carry ou business as a transport company.under the name of \"Les Transports communautaires ltée Community Transporta Ltd.\", with a total capital stock «>f 65,000, divided into Onu common shares of a nominal value of $10 each.'The head office of the company will be al 403 Sherbrooke St.Fast.Montreal, judicial «listrict «»f Montival.(iiven at the office of the Provincial Secret a i this 9th day «»f September.1965.Raymond Doi vii.i.i:.Assistant Secretary of the ProviltCt 1240!» 3971-05 'Trimen Corporation Notice is hereby given that under Part I ol the Queliec Companies Act.letters paten I.bearing «late the 1st day «»f September, 1965, have been issued by the Lieutenant-Govern\"' of the Province of Quebec, incorporating: Donald K'ujan.34S0 (ote-de-Liesse Road, Mount Royal Raymond Cartwright.71 Devon Road.Baic-d'Urfé, both advocates, Lena Switser, 4665 Carlton Avenue.Montreal, ami Micheline Bertrand, 2102 Sherbrooke West.Montreal, the latter two secretaries, lilies majeures «-t usan «le leurs droits, for the billowing purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October W, 1996, Vol.97, Ko.Li Exercer lee affaires «l'une compagnie d'immcu-hies, «!«\u2022 oonetniction et «le placements, sous l«-nom de * Tri men Corporation , avec un capital t.iial de 140,000, divise en 1,000 actions ordinaires ,1, si chacune et 80,000 net ions privilégiées «!«\u2022 si chacune.l.i siège social de la compagnie sera 7200, rue Hutchison, chambre, 304.Montréal, district judiciaire «!«\u2022 Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 1er jour descptembrc 1905.Le Sous-secrétaire île In procincc.Raymond Doi vii.i.i.12409 3914-66 Veilleux construction inc.\\vis est donné qu'en vertu «le la première partie de la I/>i des compagnies, il a été aeconlé, par le lieutenant-gouverneur de lu province de Québec, des lettres patentes, en «late du 14e jour de septembre 1005, constutiant en corporation : Rosaire Vcilleux, constructeur, Bruno Veilleux, menuisier, Jean Veilleux, menuisier, tous trois de 3105, St-Donat, Montréal, et Victor Veilleux, 2915, Des Ormeaux, Montréal, pour les objets suivante: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de Veilleux construction inc.», avec un capital total «le 540,000, divisé en 4,000 actions ordinaires «le $10 chacune.I>e siège social «le la compaguie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 14e jour de septembre 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.L2409-o 4049-00 Versailles Hair Products Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quélwc, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en «late du jour de septembre 1905, constituant eu rarporatiou: John Jacob Spector, 4840, Côtc-St-Luc, Montréal, Ben Schecter, 4300, Western, rVestmount, tous deux avocats et conseils en Loi de la reine, Mervyn Norman Rosenstein, avocat, 4090, Bouchette, Montréal, et Charles Speetor, avocat, 5230, rue Musset, Montréal, pour les objets suivants: Paire le commerce de toutes sortes de cheveux, textiles, caoutchouc, cuir, élastique, plastique, produits symthétiques et métalliques, sous le nom de « Versailles Hair Products Inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 995, rue Wellington, Montréal, district judiciaire de Montréal.I tonné au bureau du secrétaire de la province, ce 8e jour «le septembre 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.12409 .'1009-05 Wellington Supermarket Inc.Avis «-si donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, il a été aeconlé.5451 To cany ou the business of a real estate, construction ami investment company, umler the name «>f \"Triineii ( 'orporation\".with a total capital stock ur d'octobre 1959.changeant son nom en «\u2022«\u2022lui de « Webster Realties Co.Inc.Donné au bureau «lu secrétaire f Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council, by application addressed to the Provincial Secretary, for an Order in Council changing her name tt> Irene MacDnunlil.same to avail for all legal purposes.Montreal, September 21.1965.Mi-: Stanley Goldnbr, 12354-41-2-0 Attorney for applicant. MM GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, IG octobre 1906, 97' année.No L2 Corporation des Président r! Syndics de la Cumin une de Lapruirie À UUIS les censitaires de lu Commune dt Laprairie de la Magdeleîne de: ville te St.Catherine à Montr«;al s'adresse au lieutenant gouverneur en c«inseil de la province «le Québec, en vue «l'obtenir le changement de nom en celui de « Eric Moss ».Montréal, 27 .septembre 1905.12455-42-2-0 Mazkk Aszkknajzku.Corporation of the Chuirinun and Trustees of the Common of Lupruirie To all the censitaires of the Common of La prairie «le la Magdeh'iiu': t«i\\vu of La Prairie; town of Bros sard; town of Candiac; town .) Delsou; parish of St-Philippe; parish of S| Jacques !cr of its directors from 3 to 5.Mus.Marie Gilbkht Roy, Secretary.12461 14253-53 Marvel Products Limited Notice is hereby given that \"Marvel Products Limited\", has changed the number of its directors from 5 to i.K.A.Flanigan, Secretary.12462-0 2218-32 Le Fonds de Construction de Saint-Benoît-du-Lac inc.Notice is hereby given that the Provincial Secretary has, on September 20, 1965, approved the general by-laws of \"Le Fonds de Construction de Saint-Benott-du-Lac inc.\", and such, pursuant to the provisions of section 225a of the companies Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of September 1965.Raymon d Douvillk, Assistant Secretary of the Province.1246S 16088-61 5458 GAZETTE OFF ICI ELLE DE QUÉBEC, It) octobre 1906, 97' année, No LB Sièges sociaux Retter Cleaning & Laundry Fquipmciit Inc.Avis est donné que la compagnie ¦¦ Bel 1er (leaning & Laundry K«piipmrporalion\", incorporated under Part I ol Ike Quebec Companies Act by letters patent dated February 20.1962, has moved its head office from 2070 St.Luke Street in the city of Mont-real t«> 1 Place Ville Marie, room 371\").in the city of Montreal.Dated at Montreal, this 3rd «lav of September, 1985.BkTTV IssKNMAV Secret n 12433m 10985-62 Kensington Investment Corp.Notice is hereby given that \" Kensington In-vestment Corp.\".incorporated under Pari I of th«' Quebec Companies Act by letters patent dated January 8, 1959.has moved its head office from 1905 Tupper Street in the city of Montreal to 1 Place ville-Marie, room 3715, in the city of Montreal.Dated at Montival.this 3rd dav «»f SeptennVr.1965.Anne Nbrenbeho, Secretary.12434-0 10090-59 Marissa Industrial Sites Corp.Notice is hereby given that \"Marissa Industrial Sites Corp.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies Act by letters patent dated November 13.1959.has moved its moved its head oflice fTOm 2070 St.Luke Street in tin city «)f Montreal to 1 Place Ville-Marie, room 71a.in the city of Montreal.Dated at Montreal, this 3rd day of September, 1965, Arnolo Issknman.Secretary.12435-0 16172-59 Metropolitan Industrial Park Inc.Notice is hereby given that \"Metropolitan Industrial Park Inc.\", incorporated under l'art I of the Quebec Companies Act by letters patent dated duly 25.1900.has moved its- head oflice from 2070 St.Luke Street in the city of Montreal to 1 Place Ville Marie, room 3715* in the city of Montreal.Dated at Montreal, this 3rd dav of September, 1005.Arnold Issknman.12436-0 Secretary.Norman Nerenberg Corporation Notice is hereby given that \"Norman N« ren-berg Corporation\".incor|>oiuted under Part I w the Quebec Companies Act by letters patent dated February 20.1002, has moved its head office rom 2070 St.Luke Street in the city of Montreal to 1 Place Ville Marie, mom 3715.in the cityjrf Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, i960, Vol.97, No.hi i )alé à Molli real..12137-0 I.c Secretaire.1 suak.i.NbbENBEBO.10987-02 Kenneth Perry Corporal ion Vvis est.par les présentes, donné «pu- la compagnie « Kenneth Perry Corporation », constituée «mi corporation en vertu de la première partie «le la Ia>\\ «les Compagnies «le Quebec, pai lettres patentes en «late du 26 février 1962, a i importé son bureau principal «le 2070 rue St.Luke en lu cité «le Montréal à 1 Place Ville-Marie, suite 3715, en la cité «le Montréal.:>até à Montréal.«\u2022«\u2022 .'1 jour «le septembre 1965.;s.o Le Secrétaire.Ci.Alio: PeBRY.10986-62 Place Bonuvcnture Inc.Vvis est.par les présentes, donné que la compagnie « Place Bonaventure Inc.», constituée en corporation en vertu de la première pu tie «le la l.oi «les Compagnie «le Québec, par lettres patentes en date «lu 21 février 1964, » transporté son bureau principal «le 01 ô ouest, ru.Dorchester, suite 630, en la cité «le Montréal à ! Place Ville-Marie, suite 3715.en la cité de Montival.Daté à Montréal, ce 3e jour «le septembre 1965; Le Sécréta ire-trésorier.June (Iacnox.863-64 12439-0 Kcdfern Corp.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « Rcdfern Corp.», constituée en corporation, en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en «late du 7 avril 1064, a transporté son bureau principal de 2070 rue St.Luke en la cité de Montréal, à 1 Place Ville-Marie, suite 3715, en la cité de Montréal.Daté à Montréal, ce 3e jour de septembre lu.,.\".Le Secrétaire, Betty Issenman.12440e 1536-64 Reservation Investment Corp.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « Reservation Investment Corp.», constituée en corporation en vertu de la première partie er 1248 (ireene Avenue. 5102 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 10 octobre 1900, i)7' année, No 1,2 A compter de la dale du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant sou bureau principal.Donné à West mount, ce 20 septembre 1905.12112-.Le Président, ( 'l.Al'DE ( '.VDOHETTE.3718415 W iinco Steel Limitée L'Acier Wimco Limitée Avis est, par les présentes, donné (pie la compagnie « YYiinco Steel Limited \u2014 L'AcierWimco Limitée », constituée en Corporation en vertu des dis|K)sitions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, le 20e jour d'août 1905, et ayant son siège social en la ville de Montréal, en la province, de Québec, a établi son bureau à 50, place Crémazie.À compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté ce 31e jour d'août 1905.Le Secretaire, Murray Woutsman.12443 3815-05 Better I-m 111 i i » 1111 ni Inc.Avis est donné que « Better Equipment Inc.», a transporté son siège social de St-Mioliel à chambre 012, 800 carré Victoria, Montréal.12444 Le Secrétaire, Steve Kass.15641-01 Les Constructions Dionne & Dn\\al Inc.Prenez avis que le siège social de la compagnie « Les Constructions Dionne & Duval Inc.», a été fixé par résolution du bureau de direction en date du 3 juillet 1905 à 157c rue St-Antoine Nord, à Granby.Daté à Granby, ce 3 juillet 1905.Le Président, Leopold Dionne.12445-0 2509-05 Dean's Cycle & Sports Inc.Avis est donne que « Dean's Cycle & Sports Inc.», a transporté son siège social de 5899, avenue Verdun, Verdun, à 770, avenue Halpern, Dor val.Le Secrétaire, D.Colli s.12440 2621-65 Les Lu i reprises Eddy Inc.Kddy's Enterprises Inc.Avis est donné que la compagnie « Les Entreprises Eddy Inc.\u2014 Eddy's Enterprises Inc.», constituée par lettres patentes en date du 19 août 1965, et ayant son bureau principal à Terre-bonne Heights, district de Joliette, a établi son bureau en ladite ville de Terrebonne Heights.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Terrebonne, ce 1er jour d'octobre 1965.Les Procureurs de la compagnie, Lalande, Brière, Reeves, Lacoste et Paquette.12447-o 3689-65 From and after the date of this notice, the said oflice shall be considered by the company as being the head olfiee of the company.Given at Westmount, this September 29 1965.Claude Cadorem , Preside,.12442-0 3718.60 Wimco Steel Limited L'Acier Wimco Limitée Notice is hereby given that \"Winieo Sled Limited \u2014 L'Acier Wimco Limitée\", incorporated under the provisions of Part I of the Qu< bee Companies Act on the 26th day of August.1965, and having its head office in the city of Montreal, in the province of Quebec, has established its office at 50 Place Crcinazie.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated this 31st day of August, 1965.Murray Wortsmax.Secretary.12443-o 3815-65 Better Equipment Inc.Notice is hereby given that \"Better Equipment Inc.\", has transferred its head office from St-Michcl, to suite 612, 800 Victoria Square, Montreal.Steve Kas>.Secretary, 12444-o 15011-61 Les Constructions Dioiiuc & Duvul Inc.Take notice that the head oflice of the company \"Les Constructions Dionne & Duval Inc.\", has been fixed by a resolution of the board of directors duly passed on July 3, 1905 at 157c, St-Antoine Street, north, in Granby.Dated at Granby, July 3, 1905.Leopold Dionne.President.12445-o 2509-65 Dean's Cycle & Sports Inc.Notice is hereby given that \"Dean's Cycle & Sports Inc.\", has transferred its head oflice from 5899 Verdun Avenue, Verdun to 770 Halpern Avenue, Dorval.D.Collis, Secretary.12446-o 2621-65 Lea Enterprises Eddy Inc.Eddy's Enterprises Inc.Notice is hereby given that the company \"Les Entreprises Eddy inc.\u2014 Eddy's Enterprises Inc.\", duly incorporated by letters patent, dated August 19, 1965, has established its head oiliee in Terrelionne Heights, district of Joliette.As from the date fo the present notice, the said office is considered by the company as its head oflice.Given at Terrebonne, this 1st day of October, 1965.Lalande, Briere, Reeves, Lacoste and Paquette, Attorneys for the company.12447-0 3689-05 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 10, WOO, Vol.07, No.U 5463 I rain his*' Equipment Service lue.\\vis est donné que « Franchise Equipment Service Inc.», a transporté son siège social dc Si Michel a chambre 012, 800 carré Victoria, Montreal./ Le Secrétaire, Steve Kass.12448 13019-01 Frunebise Equipment Service lue.Notice is hereby given that \"Franchise Equipment Service Inc.\", has transferred its head office from St-Michel, to suite 012, 800 Victoria Square, Montreal.Steve Kass, Secretary.1244K-0 13019-01 Canada Drug Limitée \\vis est donne que la compagnie «Canada Drug Limitée», constituée en cor|>oration par r-.patentes en «late «lu 12 juillet 1954 et avant son bureau principal dans la cité de Montréal, a transjM)rté son siège social de 857 rue SI Maurice où il était auparavant, au numéro si M) boulevard St-Laurent.À «-ompter «le la date «lu présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.I tonné à Montréal, ce 15e jour de septembre l'Hi.-).Sceau) Le Secrétaire, M.BuASSEUR.12457-0 11500-54 Aqua Traitement ltée Avis est donné «pie la i-ompagnie * A«pia Traitement Ltée », constituée en corporation en \\ : t u des dispositions «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Quél>ec, en date du 25e jour de juin 1905, et ayant s«m siège social dans (Québec, district de Québec a établi son bureau au numéro 577, Ixudevard Ilamel, Québec.' À compter de la «late «lu présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme «\u2022tant son siège social.Donné à Québec, ce 24e jour «le septembre, 1065, Aqua Traitement Ltée, l'ar le Secrétaire-trésorier, Louis René Tremblay.L'158-o 2982-65 Canada Drug Limited Notice is given that \"Canada Drug Limited\", incorporated by letton patent dated duly 12, 1954 and having its bead office in the city of Montreal, has changed the address of its office from 857 St.Maurice Street where it was before, to 8480 St.Lawrence Boulevard.From and after the «late fo the present notice, the said office is considered by the company as being its head oflice.Given at Montreal, this 15th dav of September, 1965.(Seal) M.Bkasseur, Secretary.12457-.) 11560-54 Vqua Traitement Ltée Notice is hereby given that \"Aqua Traitement Ltée\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies Act on the 25th day of June, 1965, ami having its head office in Quebec, district of Quebec, has established its office at number 577 Ilamel Blvd., Quebec.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the bead office of the company.Given at Quebec, this 24th date of September, 1965.Aqua Traitement Ltée, Per: Louis René Tkemulay, Secretary-Treasurer.12458-0 2982-6Ô Marché St-Louis (Trois-Rivieres) Ltée lvil est donné «pie la compagnie «Marché St Louis (Trois-Rivières) Ltée , constituée en corporation par lettres patentes, le 26e jour d'août 1965, et ayant son bureau principal à Trois-Rivières, a établi son bureau au numéro ¦ 16 avenue de l'Église, Trois-Rivières.A compter de la «late «lu présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté à Trois-Rivières.ce 4e jour d'octobre 1065.Le Président.Paît.Joibahm:.12463-0 3242-65 Marché St-Louis (Trois-Rivières) Ltée Notice is hereby given that '\".Marché St-Louis (Trois-Rivières) Ltée\".incorporated by letters patent, on the 26th day of August 1965, ami having its head office in Trois-Rivières.has established its office at 1636 «le l'Eglise Ave, Trois-Rivières.From and after the «late of this notice, the said office shall be considered by the company BS being the head oflice of the company.Dated at Trois-Rivières.this 1th day «»f October 1965.paul Joibaunk.President.12463-0 3242-65 Marcoux Construction Inc.Vvis est donné que « Marcoux Construction Inc., a été constituée en corporation en vertu de la première partie «le la loi des compagnies de Quebec par lettres patentes datées le 24 août 1965 et que son siège social est situé à 1128 Mgr-Bourget, ville «le Laval, province de Québec.Montréal, le 4 octobre 1065.Sceau) Le Président, Armand Marcoux.12464-0 3758-65 Marcoux Construction Inc.Notice is hereby given that \"Marcoux Construction Inc.\".was incorporated under the provisions «>f Part I of the Quebec Companies Act by letters patent dated August 24, 1965 and that its head office is situated at 1128 Mgr Bourget.town of Laval, province «>f Quebec.Montreal, October 4.1905.(Seal) Armand Marcoux, President.12464 3758-65 Ô404 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Hi octobre t966, 97' année, No J,2 Garage Lucien Inc.Avis eat donné que lu compagnie « Garage Lucien Inc.constituée en corporation en vertu da la première partie de la Loi dee compagnies «le Québec par lettres patentes en date du 10 août 1001, a transporté son siège social de 0007.(îarnier, en la ville de Montréal, à 4X09.rue St-Denis.en la ville «le .Montré'al.Montréal, «r 7e jour «le septembre 1965.(Sceau; Le Seerétaire.Haiihy Ramm.12460 14127-01 Salaison Lafonlaine Packing Inc.Avis est donné «pie la compagnie « Salaison l.a fou ta n n- Packing Inc.», constituée en corporation en vertu «le la première partie «le la I/»i «les compagnies «le Québec, par lettres patentes, en «late du 27e jour «le janvier 1055, et par lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 0e jour «le septembre 1056, a établi son siège social à 5020, rue Belleclias.se.est.en la ville «le Montréal.Montréal, ce 4e jour «le mai 1065.(Sceau) l.e Secrétaire.Shirley Le vine.12466 10240-55 Service Régional des Bibliothèques de West-Island West-Island Regional Library Service Avis est donné que \"Service Regional des Bihliothètpic.s «le West-Island \u2022 West-Islaiul Regional Library Service », constituée en vertu de la troisième partie de la Loi «les compagnies «le Québec, par lettres patentes en «late «lu premier jour d'octobre 1904.a établi SOU siège social 461, Montée St-Jean, en la cité de Pointe Claire, district «le Montréal.Pointe Claire, 30 septembre 1965.(Sceau) Le Secrétaire.Catherine R.Baud.12470 4220-64 Garage Lucien Inc.Notice is hereby given that \"Garage Lucien Inc.\", incorporate*! under Part I of the Quebec < 'oiopauies Act by letters patent «late«l Align t 10, 1901 has moved its head office from 6697 Gamier, in the city «>f Montreal to 4869 st.Denis Street, in the city of Alontreal.Montreal, this 7th day of September, 1965.(Seal) Hahuv Ramm.Sccretan/ 12466-0 14127-01 Salaison La fontaine Packing Inc.Notice is hereby given that \"Salaison Lafon taine Packing Inc.\", incorporated under Pari I «»f the Quebec Companies Act by letters pah date I 27th day of January.1955, ami by supp mentary lett«-rs patent dated tit h day of Sept her, 1956 has established its head office at 5020 Bellechas.se Street Kast.in the city of Montre !.Montreal, this 4tb day «>f May.1965.(Seal) Shirley Levine, Secretary 12466-0 10240 ôô Service Régional des Bibliothèques de West-Island West-Island Regional Library Service Notice is hereby given that \"Service Régional des Bibliothè«pies de West-Island - -West-Island Regional Library Service**, incorporât I uiuler Part III of the Quebec Companies A« t, by letters patent dated the first day of Octol t 1904.has established its head office at 4ô 1 Montée St-Jean.in the city of Pointe Claire, (lis.trict «>f Montreal.Pointe Claire, September 30.1905.(Seal) Catherine R.Baku.Sccretan, 12470-0 4220-04 Curatelle publique Publie ( li ira I ors hip Raymond Rousseau ( an;ela.Province de Québec, «listrict «le Québec, succession vacante «le Raymond Rousseau, en son vivant «le St-Nicolas, comté «le Lévis.Le soussigné donne avis que cette succession a été déclarée vacante en vertu d'un jugement rendu le 5 mars 1065 par un juge de la cour supérieure siégeant à Québec dans le «listrict de Québec que, sous l'autorité de la loi de la curatelle publique (9 Geo.VI, c.02), il est curateur «l'office à cette succession, et qu'il recevra, à redresse ci-dessOUS, le paiement «le toute dette envers la succession et la preuve «le toute réclamation contre elle.Le Curate un Publique.880, me Ste-Catherine (Ouest).Montréal IX.I2440-O Raymond Ron-eau Canada.Province of Quebec, district of Que-bec, Vacant estate of the late Raymond Rousseau in his lifetime of St-Xicolas.county of Levis.Notice is hereby given that this estate has been declared vacant by judgment reiulered on Alan \u2022 5.1905 by :» judge of the Superior Court, sitting at Quebec in the «listrict of Quebec that, under the authority «>f the Public Curatorship Ad (9 Geo.VI, c.02).I am ex officio curator such vacant estate, and that I will receive, nl the address mentioned below, payment of an) debt owed this estate ami proof if any claim against it.Public Curator.0X0, St.Catherine St.West.Montreal IX.12449 Demande à la Législature Application to Legislature Ville de Scheflervillc Town of Schcflerville Avis est par les présentes donné que la « Ville Notice is hereby given that the \"Town ul «le Schefferville », dans le territoire du Nouveau Sehefferville\", in the territory of New Quebec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, 1965, Vol.97, No.4$ 5405 Québec, s'adressera ù la Legislature f the mayor anil aldermen appointe«l under section 8 of the Act to organize mining towns beyond the term auth«>rizc«l by section 9 of an Act respecting the town of Schefterville 9-10 Elizabeth II, eh.128, and for other purposes, (iiven at Quebec and Sept [les, this thirtieth day of September, 1905.St-Laurent, Monast, Dr.s.MKi'i.Ks & Wai.tkks, 12836-41-4-0 Attorneys for j>etitioner.Examen des Agronomes Agronomists Examination La Corporation des Agronomes de la province de Quéhcc ASeiRAHTS À i.'ktidk di i.'.ujhonomik c in did atm TO thk BffOtrf op .\\f the last institution where they have studied.Noms et prénoms Names and surnames traenault, Jules-André Ha ilia rsjsroUi Francois Bates, Donald Leslie Heauregnrd.Guy I merer.Martin Blackburn, Mnjetln Doucher, Paul-André .BouJaasjsr, (olios IkairaaSJBS, Jean-Yves.Boursjst, Gilles .\"\u2022' i'aulf.Yves iason, Jean.: nlimuller.Francis J.\u2022 ut 1er.William J.i-toiiRuay.Gilles l liamlxrland.dinette.1 liarland.André.\u2022 .' liarron.Edouard dit Fd«l.\\ mu me, Michel.lOUSt.Georges.i '«-Liste.I.i nu-.Hour, Gérard .' ipuis.Gilles lUTOVka, Andrew \u2022tier.Michel i m tier.Valère.1 iguon, l'iiiiivoii*.¦ Bjnon, Henri-Louis égoire Y van Domicile Residence Bonaventure .L'Ange Gardien, comté de liouvillc 284 Neptune Blvd.Dorval.Baieville.comté d'Yamaska .687 ouest, rue St-Cyrille, app.3.Québec minii|uc Racine «le Chicoutimi.École Seeoinicilc Itesidenee Roe, ( hristophci Rouillard, Lena Rousscllc.Gilles Ben ne vil le, Viannes st«»rl>.Ingeborg Tahi, Mart on TewsJor, André Vàchon, ( loiloi Vésina, André Ward.Gilbert.Ztska, Jean Bélisle, Pierre l'orticr.Paul D.Lennon, Ayton s.Toaster.Jcnn-Claudi lc.it.no 3, Coatioooki oomté df Stall-lead.Bt-Ulrio, oomté de Matane.Village des i luron.-, comté «le Qua* be«-.I.aeadie.comté de St-.lean.Mont-Carincl Valmoiit.comté de « hainplain 9004, boul.Queen Nord.Sherbrooke.Rousseau Mill-, comté de Portneuf 213, rue de l'Ormiere, Neufcbâtel, Quéheo.MM!», rue Mercure.I'lc.-.-i.-ville.comté «le Mégantic St-« \\ rille.comté de L'Islet.Rang 'l < 'oinmcrcinlc.I.a TuqUOi comté de Laviolette.St - François de Viger, comté de Ri-vière-«lu-I.oup .St-Alexis.comté de Montcalm.Ill Cambridge Road, Haie d'Urfé St-Jean de Dieu, comté «le Rivière- du-Loup.3434 Stanley Street, Montréal \u2022_' 830.rue Coniinerciale, St-David, comté de Lévis.77ii.2e Rue.Iberville.31.rue St-Christophe.St-Félicicn.comté du Lac St-Jean .113 Aères Road, Beacionsfkild 2(i4, rue Château d'Eau.Loretta- ville.Rue Principale.Ste-Fli.-alh-lh.com-té de Joliette C.P.103.Black Lake, comté d« Mégantic.1796, boul.Ma-.-on.Les Saule.-, comté de Québec .St-Sauveur, comté de Gloucester, N'ouveau-Hrunsw ick.897, ave Notre-Dame.Notre-Dame Luirentiiles, comté de Québec 100.boul.Richelieu, St-Mathias.comté «le Kouville.Boa S», Melbourne, «-ounty of Richmond.2570.rue de la Falaise, Sillery, Québec .1966.JjBAN-Louia I)«n «i.i.«i. 29 septembre 1965.Le Sous-ministre.12451-0 Pernano Boutin.Township of Luaaier Official cadastre «>f the township «>f Lumier, municipality of Saint-Donat *.registration division of Montcalm.Notice is hereby given that lots 20-a, 20-b, 21-a.21-b, 22-a.22-b.23-a.23-b.2l-a.24-b, 25-a, 25-b.20-a, 20-b, 27-a, 27-b.2S-a, 2S-b, 29-a, 29-b, 30-a, 30-b, 31-1, 31-2.Range VI arc cancelled and lots 19.32-1.32-2.Range VI and Blocks A ami B arc corrected in virtue «»f Article 217IA of the Civil Code.Quebec, September 29, 1966.Kkknam) Hoi tin, 12451-0 Deputy Minister.Ministère des Department of Affaires immieipales Municipal Affairs 5468 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 10 octobre 1965, 97' année.No Li Canton Ac lus.il Cadastre officiel du canton de Laval, municipalité de Sl-Luc «le Laval *, division d'enregis-t renient de Saguenay.Avis est par la présente donné que le lot K-B-l, Rang IX est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 22 septembre 1905.Is Sou*-ministre, l'2451-o Fkhvani» Boutin.Paroisse «le Ste-Thérèse de Blainville Cadastre olfieiel de la paroisse de Ste-Thérèse de Hlaiiivillc imiuieipalité de la cité de Ste-Thérèse.division d'enregist renient de Terre-bonne.Avis est par la pré-sente donné que les lots 239-1 à 239-07 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le '22 septembre 1905./«e SoiM-iiiiiiintre.1245l-o PeuNANO Boutin.Township of Laval Officiai cadastre of the township of Ijival.municipality of St-Luc «le Laval*, rcgistra tion division of Saguenay.Notice is hereby given that lot K-B-l, Han.IX is cancelled in virtue of Article 2174A of tl e Civil Code.Quebec, September 22.1965.Fkhnand Bot tin.12451-»» Deputy Minister Parish of Ste-Thérèse de Blainville Official cadastre of the parish of Ste-Thérèse Blainville, municipality of the city of St Thérèse, registration divismi of Terrebom Notice is hereby given that lots 239-1 to 239-07 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, September 22.1965.Pern and Boutin, 12451-»» Deputy Minister Ventes pour taxes Sales for Taxes Cité de Hull Avis est par les présentes donné par le soussigné.Greffier de la Cité que les propriétés immobilières ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique, le DOUZE NOVEMBRE 1965.à DIX heures de l'avant-midi, dans la salle municipale de l'Hôtel de Ville «le la Cité de Hull, à défaut «le paiement «les taxes municipales et/ou scolaires, ainsi que les frais encourus.City of Hull Notice is hereby given by the undersign-11 City Clerk of the City of Huli, that the immovable properties hereunder ilescrilied will l>e sold by public auction, on NOVEMBER TWEI/111 1965, ut TEN o'clock in the forenoon, in t lu-municipal hull of the City of Hull, in default of payment of municipal and/or school taxes and coete incurred.Quartier Laurier\u2014 banner Ward No Role Roll No.118.188.272 305 898, 431.518.885.528.880.Propriétaires \u2014 Adresses Proprietors - - Address Kubiiaille, Jean-Claude, et-und Mine,-Mra, Yvon et-und Mine-Mrs, Lemieux.Yvou et-and Mme-Mrs (Cuisse Populaire de Hull).229/231.Pupineau.Beuudoin, Alfred, (Pierre Des Hosiers), 8, Verdun.St-Martin.Lionel, (Caisse Populaire Sacré-Coeur), 180, Sacré-Coeur.St-Arnuud, Léo, (L't'nion du Canada Life Assurance Vie), 212, Luvul.Périard.Puul-Emile et-and Mme-Mrs.(Murie-Louise Sirois et-and Club de Sulaberrv Inc.).119, Kent.Vaillant, Gaston, (Emile Laurin), 132 Kent.Gauvreau, Ambroisc, (Jacques Lufraiu-boise, in trust), 111, Dollurd.Lépinc, Julien, (St.Louis Investment Corp.), 80 Dpllard.Hobituille, J.-Edounrd.(Suce.Françoi» A.Hi n et .143, Maison neuve .Hobituilles, Ls-Georges et-and Edouard, M uisonneuve.Nicholas, Klzéar et-and Mme-Mrs, (Roland St-Onge et-und Dame Emeren-tienne Hélisle Hrii'-rei, 207, Maison neuve.5.5 5.5 5.4.4.4 Numéro du cadastre Cadastral number 70-2.O-W.410.N.K.181.217-F-21.N-518.N-498.S-487.39-1 .69-1 .43-2 .B-454 Taxes munie.Munie.taxes 81.431.37 124.99 «25.28 249.80 474.87 69.80 Taxas scol.School taxes 312.30(C) 122.93(C) 126.08(C) 67.47(C) 55.56(C) 248.61(C) 89.44(C) 191.49(0 21.28(C) 61.66(C) 1.80 Frais Costs 8180 1.40 1.40 1.40 1.80 1.40 1.40 1.40 1.40 1.00 Total $1.740.17 124.33 186 127 l 69.88.01 876.21 340 t.; 887.71'\" ni « 68.46 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 10, 1966, Vol.97, No.1,2 -Am Quartier Laurier (tuile) \u2014 Laurier Ward (continued) Propriétaires \u2014 Adresses Proprietors Address (îiievreincnt, Arthur.(Cais.se Populaire du Sacré-Coeur de Hull), 267, Maison-neuve .I ink loi i'i ii, Mme-Mrs Louis, (Sidney Krwiiui Michael Greenberg), 287/289, Ma Ï8on neuve.St-Denis, Mme-Mrs Joseph, 262.Maison-neuve .Itobitaille, J.Claude et-and Yvon, Lemieux, Yvon Mme-Mrs, (Caisse Populaire de Hull), Maisonneuve.Hohitaille, J.-Claude et-and Yvon, Lemieux, Yvon, Mme-Mrs.(Caisse Populaire de Hull)., 100, Maisonneuve.Kobitaille, Jos Edouard, (Shell Oil Company of Canada), 150, Maisonneuve Lutour, Aimé et-and Lutour.Félix, Mme Mrs, 253-255, Champlain.(iuindon, Aurèle, (Rév.J.-Romco Guin-don) 309.Champlain.Hobidoux, Olivier, Mme-Mrs.399.( \"hum-phi in.Rémillurd, Louise.Luc, Paul et-and Mme-Mrs Ariette, Gabriel, Bernard et-and Mme-Mrs., Perron, Raymond et-and Mme-Mrs., 100, Champlain .Chéné.J.-Dosithé, (Caisse Populaire de Hull), 1G3, Notre-Dame.Cyr, Hubert.(The Royal Trust Company \u2014 Caisse Populaire de Hull \u2014 Armand Brière, 175/177, Notre-Dame.Pilon, Aldoria, (Seaboard Securities Canadian Ltd.), 204.Notre-Dame.n ItS Numéro\tTaxes\tTaxes\t\t\t\t du cadastre\tmunie.\tscol.\t\tFrais\t\t \t\u2014\t\u2014\t-\t\t\tTotal Cadastral\tMunie.\tSchool\t\t( !oauj\t\t niinilxT\ttaxes\ttaies\t\t\t\t N-381\t\t$ 68\t28(C)\t1\t40\t* 66.68 217-D-2.\t\t285\t66(F)\t\t80\t1,262.70 Pt.S.279.\t\t\t\t\t\t Pt.290 .\t$171.46\t10\t80(C)\ti\t60\t213.85 Pt.N.18.\t60.30\t21\t28(C)\tl\t80\t82.88 S.18.\t777 37\t514\t43(C)\ti\t80\t1,288.60 44-2.\t213 36\t75\t64(C)\t1\t40\t290.40 S-328.\t\t119\t38(C)\tl\t00\t120.38 N-209 .\t316.89\t121\t75(C)\ti\t40\t440.04 N-00.\t262.61\t84\t95(C)\ti\t00\t358.50 46-2.\t253.53\tw\t86(G)\tl\t40\t353.88 .8-2.\t899.38\t3.50\t65(C)\ti\t40\t1,251.38 E.537.Pt.\t\t\t\t\t\t 530.\t668.61\t248\t22(C)\t2\t80\t900.63 \t\t186\t33(C)\t1\t40\t137.73 \t\t\t\t\t\t Quartier Frontenac - Frontenac Ward Boivin.-Philippe, Mme-Mrs, (Caisse Populaire de Hull), 151, Papineau.St-Louis, Paul, (Caisse Populaire de Hull), 07.Papineau.St-Louis.Paul, 67, Papineau.Sa bom in.Emile ot -and Mme-Mrs., (Martin Investment Corp.), 68/70, Garnenu Trépanier.Donat.(Stanley F.Cross et-and Succ.-Kst., Dame II.C.Cross) 96, Garnenu.Custugne, Mme-Mrs Charles, (H.Blackburn & Cie Ltée \u2014 Société d'Fntrepri-se du Canada), 115, Garnenu.Leduc, Lucien, (Dame F.va Bornall Pen-noek), 79, Garnenu.Saucier, Rosario, (John K.Graham el ni) 51, Gurneau.\u2022.Majeau, l'rgel, (Caisse Populaire Ste-Bernudette de Hull), 9, Garneau.Gravelle, René, 24, Charlevoix.Cole, Mme-Mrs Albert.(Kenneth Mc-Ewen), 30, Charlevoix.Paquette, Jean-Paul et-and Mme-Mrs (La Corporation Crédit Communau-taire (Inc.), 40, Charlevoix.Bigrns, Gilles, (Caisse Populaire Ste-Ber-nudette de Hull \u2014 Roland IVudhom-me), 90, Charlevoix.Lévesque, Elzéar, 107, Charlevoix.Assistance Loan & Finance Corp., (Ideal Concrete IVoducts Co.Ltd.\u2014 Bourque Frères Ltée \u2014 Laurence Investment Ltd.), 99, Charlevoix.Beuuchump, Marcel et-and Mme-Mrs.(Cuisse Populaire Ste-Bernadette de Hull).171, St-Laurent.Lnfontaine, Joseph, (Banque Royale du Canada), 129, St-Lnurent .Deschamps, Mme-Mrs.Maurice, (Ottawa Prestige Investment Ltd.\u2014 Dame Oscar Robillard), 127, St-Laurent.La bonté, Arthur, 52-54.St-Etienne.192-2, 884,.\u2022 96-1-1, 96-3-2 sur 96-4-1, 96-3-2____ 96-0.28 172-1 101-1 152-2.96-33-1 96-89A 96-46A 96-47B 96-50A 143-1.134-1.130-P sob.131-6.123-2.124-1 132-1.188-8 133-2 135-7-1 $510.09 230.82 741.24 255.47 135.28 268.68 168.59 475.53 255.62 248.75 799 18 265.42 328.40 $67.77(C) 216.30(C) 278.54(C) 133.03(C) 121 80(C) 158.57(C) 95.35(C) 92.20(C) 84.71(C) 53.98(C) 200.10(C) 165.08(C) 46.29(C) 72.91(C) 382 80(C) 316.76(C) 151.30(C) 73.74(C) $2.00 2 00 1.60 1.40 1.80 1.80 1.40 1.40 1.40 1.00 1.40 1.40 1.80 1 60 2.20 2.00 2 00 1.80 1.00 5470 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre I960, 97' année, No L2 Quartier Fronteoae (tuite) \u2014 Frontenac Ward (continued) No\t\th\tNuméro\tTaxes\tTaxes\t\t\t Rôle\tPropriétaire- Ailros.se>\tMm\tdu cadastre\tmunie.\tscol.\t\\\trais\t \u2014\t\u2014\t\t\t\u2014\t\u2014\t\t\u2014\tTotal Roll\tProprietors - ¦ Address\t1*\t( 'adastral\tMunie.\tSchool\t(\"osts\t\t No.\t\tc\tDumber\ttaxes\ttaxe-\t\t\t l'iâ 7\tNault.Hhéal.(Caisse Populaire de Hull\t\t\t\t\t\t\t \tDaine Donut St-Martin \u2014- Maurice\t\t\t\t\t\t\t \t< la ut hier).52, Nacré-Coeur.\t3.\t13-1.13-2-1 .\t\t6125 47(C)\t$2\t.80\t8 12S / L969.\tGroulx, Francois, (Cirant Blondin - Gaé-\t\t\t\t\t\t\t \ttan Logault), 60, Boni.Sacié-( 'oour .\t3.\t13-16.\tSi ,898 60\t686 80(C)\t1\t.80\t1,982 M IBM 1\tPlacements Bonaido Ltée, 13, Falardeau.\t8.\t\t\t131 54(C)\t1\t00\t132 54 \tProulx, Kuclido, (Stanley E.Cross ¦\t\t\t\t\t\t\t \tWin.C.Créai-Union Finance Co.\t\t\t\t\t\t\t \tLtd A.Morin.\t2.\t93-25-1.88-\t\t\t\t\t \t\t\t26-1.\t\t80.78(C)\t2\t80\t33 63 81,87.\u2022\tProulx, Kuolido, (Stanley E.Cross *\t\t\t\t\t\t\t \tWin.C.Croas \u2014 Union Finance Co.\t\t\t\t\t\t\t \tLtd.).81.Morin.\t\u2022j\t88-86-8.98-\t\t\t\t\t \t\t\t26-2.\t\ti m 26(C)\t\tvo\t143 00 2145\tPharaiid, Mendoza, 103, St-Hédeinptciir.\t2.\t90-1-1.\t\t161 83(C)\t1\t00\t162 2202\tI/cblanc.Oscar.272.St-Kédcmpteur\t3 .\t10-7-1\t217 89\t7o 80(C)\t1\t00\t888 j 2217\tHamelin.Kmmanuel, (Suce.Aima Mer-\t\t\t\t\t\t\t \tcier), 230, St-Hédempteur.\t3\t51-2.\t273 68\t166.61(C)\t1\t40\t431 nu 2230 .\tBeauchainp, Marcel.St-Itédcmptcur\t3.\t120-1.\t\t70.40(C)\t1\t00\t77 In 3868\tMonette.Eusèbe, Mme-Mis.(Chéri Iji-\t\t\t\t\t\t\t \tplante).35-37.St-Hyacinthe.\t3.\t63.\t\t130 99(C)\t1\t40\t132 10 2202 .\tChénicr.Charles.(Dame Albert e Dai-\t\t\t\t\t\t\t \tgneauit Bénéeai \u2014 Banque Royale du\t\t\t\t\t\t\t \tCanada - J.Freedman & Sons Ltd.)\t\t\t\t\t\t\t \t59, St-Hyacinthe.\t8\t24-1\t\t81.96(C)\to\t20\tS4 la 2203.\tChénier, Charles et-and Mme-Mrs, (Da-\t\t\t\t\t\t\t \tme Alberto Daisjneault Bénéeai \u2014 Ban-\t\t\t\t\t\t\t \tque Royale du Canada \u2014 J.Freer before being assigned to proof reading).Compagnon opérateur de fondruse: (doit pouvoir se charger .complètement des fon-«louses et claviers, sans obligation d'être opérateur «le clavier)\u2014Casterman: (mtist he capable of taking complete charge of casters and keyboards, but need not be keyboard operator).Aide stir fondeuse \u2014 Caster runner: 1ère année \u2014 1st year: 1er six mois \u2014 1st six months.2e six mois \u2014 2nd six months.2e année \u2014 2nd year: 1er six mois \u2014 1st six months.2e six mois \u2014 2nd six months.Zone I\t\tZone II\t\tZone III\t Taux\tTaux\tTaux\tTaux\tTaux\tTaux de\tde\tde\tde\tde\tde jour\tnuit\tjour\tnuit\tjour\tnuit Day\tNight\tDay\tNight\tDay\tNight rates\trates\trates\trates\trates\trates $2.58\t$2.00\t$2.36\t$2.68\t$2.26\t82.5S 2.58\t2.90\t2.36\t2.68\t2.26\t2.58 2.58\t2.90\t2.36\t2.68\t2.26\tïM 2 58\t2 90\t2 36\t2 68\t2 26\t2.58 0 82\t0.94\t0 72\t0.83\t0.68\t0 79 0.84\t0 96\t0 75\t0.86\t0.71\t082 0.90 0.03 1.03 1.07 0.79 0.82 0.90 0.95 0.77 0.78 0.88 0 89 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, 1965, Vol.97, No.42 5481 ¦< XIX.\u2014 T.ux minima de 8alairkk Zone I Minimum hourly rates À compter du 14 novembre 1965 From November 1 ',, 1966 Zone II Zone III .',183 A compter du 14 novembre 1965 From Sovember 14, 1966 « XIX.\u2014Taux minima de salaires Minimum hourly hates Opératrice: machines à poinçonner; machines à brocher; machines à combo; machines à numéroter; machines à perforer; tables à assembler: machines à faire les coins ronds aux COUVertures remployées; machines à poser les feuillants de calendriers; machines à coller de moins de 24 pouces de largeur \u2014 ( Iperating: punching machines; stitching machines; sewing machines; eycletting machines; nunil>ering machines; perforating machines: gathering tables; ronnd-cornering machines as used on hook-cases, or covers; tinning machines; pasting machines less than 21 inches in width.Ç1 31 Apprentie Apprentice (female): \\a' nombre d'apprenties ne doit pas excéder le tiers du nombre total des salariées.Toute personne ayant moins de 36 mois d'expérience est considérée comme apprentie \u2014 The number of apprentices shall not exceed one third (§) of the total number of female employees.Any person having less than thirty-six (36) months experience at the trade shall l>e considérée! as an apprentice: 1ère année \u2014 1st year: 1er six mois \u2014 1st six months.0 71 2c six mois \u2014 2nd six months.0.78 2c année \u2014 2nd year: 1er six mois \u2014 1st six months.0 87 2e six mois \u2014 2nd six months.0 96 3c année \u2014 3rd year: 1er six mois \u2014 1st six months.1.03 2c six mois \u2014 2ml six months.1.10 i.Apprenti (Ateliers de composition, réglage, coupage, reliure et finition) \u2014 Apprentice (Composition, Ruling, Cutting, Bindery and Finishing Departments) : 1ère année \u2014 1st year: 1er six mois \u2014 1st six months.0.80 2e six mois \u2014 2nd six months.0.83 2e année \u2014 2nd year : 1er six mois\u2014 1st six months.0.88 2e six mois \u2014 2nd six months.0 90 3c année \u2014 3rd year: 1er six mois \u2014 1st six months.1.11 2e six mois \u2014 2nd six months.1,21 4c année \u2014 4th year: 1er six mois \u2014 1st six months .1.31 2e six mois \u2014 2nd six months 1 47 6e année \u2014 5th year: 1er six mois \u2014 1st six months.1.75 2e six mois \u2014 2nd six months.1.91 6e année \u2014 6th year : 1er six mois \u2014 1st six months.2.03 2e six mois \u2014 2nd six months.' 2.17 ii.Atelier d'impression (toutes presses) \u2014 \u2014 Press department (all presses) :.1ère année \u2014 1st year: 1er six mois \u2014 1st six months.0.82 2e six mois \u2014 2nd^six months.0 98 Zone I Zone II Zone III Taux\tTaux\tTaux\tTaux\tTaux\tTaux de\tde\tde\tde\tde\tde jour\tnuit\tjour\tnuit\tjour\tnuit Day\tNight\tDay-\tNight\tDay\tNight rates\trates\trates\trates\trates\trates i) SI 51 51 19 SI 37 81 11 SI 31 0.82 0 89 1 00 1.11 1.19 1.26 0.92 0.95 1.01 1 03 1 27 1.40 1 51 1 68 2.00 2 20 2.33 2.49 0.94 1.13 0 67 0.70 0 S3 0 95 0.99 1.07 0 77 0.81 0.96 1 09 1.13 1.23 D f>3 0 68 0 79 0.89 0 93 0.98 0.72 0.75 0.79 0.82 1.00 1 09 1 16 1 29 1.59 1.65 1.71 1.85 0.70 0.84 0.83 0.86 0.90 0.95 1.14 1.26 1 33 1 48 1.83 1 90 1.96 2.12 0.81 0.97 0.68 0.71 0 77 0.78 0.99 1 06 1 13 1 26 1,52 1.58 1.65 1.76 0.62 0.77 0.90 1 03 1.07 1 12 0.79 0.82 0.88 0 89 13 22 30 15 75 .82 1 90 2.03 0.71 0.88 5481 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre 1965, 97' année.No A compter du 14 novembre 1965 From November 1/,, 1965 « XIX.-\u2014Taux minima de salaires Zone I Zone 11 Zone III Minimum hourly rat km Taux Taux Taux Taux Taux Taux de de de de de de jour nuit jour nuit jour nuit Day Night Day Night Day Nigh! rates rates rates rates rates rates 2c année \u2014 2nd vear: 1er six mois \u2014 1st six months.$1.15 $1.82 $1 00 $1.14 $0 08 $1 07 2e six mois - 2nd six months.1.34 1.55 1.13 1 30 1 00 1 22 3c année \u2014 3rd year: 1er six mois \u2014 1st six months.1.51 1.74 1.29 1.48 1 21 1.39 2o six mois 2nd six months.1.07 1 92 1 45 1 87 1 34 1 64 4c année 4th year: Ier six mois \u2014 1 st six months.1.87 2 15 1.61 1 k5 L.50 1 72 2e six mois- 2nd six months.2 04 2 35 1 73 2 00 1 63 1.87 ji.Presses groupe B-i Presses, group B-i: 6a année 5th year.2.Hi 2 48 1.76 2.03 173 2 00 ;icannée 6th year.2.17 2.49 1 77 2.04 1.74 2.01 7e année 7th year.2.21 2 53 1 S3 2 10 1.75 2 02 iv.Presses groupe B-ii et groupe B-iii \u2014 Presses, group B-ii and group B-iii: 5e année - 5th year.2 23 2 55 1.87 2.15 1.77 2.04 8e année \u2014 6th year.%.35 2 67 2 02 2.32 1.88 2.16 7e année ¦- 7th year.2.47 2.79 2 19 2 51 2 04 2.34 5° L'emploi suivant est ajouté après l'emploi 5.In section XIX-A (Composing Room), the « Correcteur d'épreuves » qui apparaît à Parti- item listed as \"Proof reader\" is immediately cie XIX-A (Atelier de Composition): followed by the following occupation: X compter du 14 nonmhre 1966 From Sorember 14.1.9(15 tente I II lit I II III Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux de de de de de de de de de.de de de jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit Day Sight Day Xight Day Night Day Night Day Night Day Night rate rate rate rate rate rate rate ratt rate rate rale rate « Tireur d'épreuve de reproduction \u2014 Reproduction proof press operator .12.50 $2.82 $2.25 $2.57 $2.15 $2 47 $2.58 $2.90 $2.36 $2.68 $2.26 $2.5S 6° L'emploi suivant est ajouté à la fin de cha- 6.The following occupation is added at the cun des groupes i, ii et iii qui apparaît à l'article end of each group i.ii and iii listed in section XIX-B (Atelier d'impression): XIX-B (Press Room): À combler du 14 naicmbre t98S From Xovcmber 1 ',.1665 Zones I II III I II 111 Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux Taux de de de de de de de de de de de de jour nuit jour nuit jour nuit jour jour nuit jour nuit jour Day Xight Day Xight Day Xight Day Xight Day Xight Day Night rate rate rate rate rate rate rate rate rate rate rati: rate « Margeur (presse» margées à la main \u2014 Feeder (hand fed presses).$1.75 $2.01 $1.55 $1.78 $1.55 $1.78 $1 NI $2.08 $1 88 11.87 81.88 $1.87\" Le Greffier du Conseil Exécutif, Jacques Prémont, 12471-o Jacques Prémont.1247l-o Cleric of the Executive Council.Arrêté en conseil Order in Council Chambre du Conseil Exécutif Executive Council Chamber Numéro 1996 Number 1996 Section « B » \\ Section \"fi\" Québec, le 6 octobre 1965.Quebec, October 6, 1965.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Present: The Lieutenant-Governor in Council.I Concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments to the decree re spec- aux débardeurs du port de Sorel.ting Longshoremen of Sorel Harbour. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, 1966, Vol.97, Xo.42 5185 Attendu quk, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux lébardeurs «lu port de Sorel, rendue obligatoire par le décret numéro 94 du 25 janvier 1951 et amendements, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 10 juillet 1965; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation dee modifications proposées; li.est ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 94, soit, modifié comme suit : 10 L'énumération des parties contractantes le première part est remplacée par la suivante: D'une part: Brown & Ryan Limited; (ullen Stevedoring Co.Limited; Eastern Canada Stevedoring (1963) Limited; Kmpire Stevedoring Co.Limited; North American Elevators Limited; The Montreal Ship Lining Co.Limited; Wolfe Stevedores Limited; Sorel Dock & Stevedoring Co.Limited.» 2° Les articles I à XIX sont remplacés par les suivants.Article I.Définitions: a) Le mot « débardeur » désigne toute personne affectée au travail manuel du chargement ou du déchargement d'un navire.6) Le mot « chargeur de wagons » désigne toute personne affectée au travail manuel du chargement ou du déchargement de wagons antres que les wagons de grains.c) Le mot « pointeur » désigne toute personne affectée au pointage des cargaisons ou au travail de bureau pour les navires.d) Le mot « tonnelier » désigne toute personne affectée à la réparation des cargaisons.Article II.Champ d'application: a) Champ d'application industriel: Le présent décret régit le chargement et le déchargement de tout navire affecté à la navigation océanique, intérieure et côtière, le chargement et le déchargement des wagons, le chargement et le déchargement des camions pour les messageries maritimes, le travail des pointeurs et des tonneliers dans le port de Sorel, définis dans le présent décret.b) Champ d'application territorial: Le champ \u2022 l'application territorial du présent décret comprend tout le port de Sorel délimité par un arrêté ministériel du Gouvernement fédéral en date du 22 février 1933.Article III.Salaires: a) Chargement du grain: Les taux de salaires pour le chargement du grain apparaissent au paragraphe 1° de l'annexe A » pour 1965, de l'annexe « B » pour 1966 et de l'annexe « C » pour 1967.b) Déchargement du grain: Les taïuc de salaires pour le déchargement du grain des navires ¦ ' .'.niques et des grands lacs aux silos apparaissent au paragraphe 2° de l'annexe « A » pour 1965, de l'annexe « B » pour 1966 et de l'annexe « C » pour 1967.c) Chargement et déchargement de certainee cargaisons: Le» taux de salaires pour le charge- WhEBEAS), pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Québec 1941, chapter 103 Bud amendments), the contracting parties to the collective labour agreement respecting Longshoremen of Sorel Bar* l>our (made binding by decree number 94 of January 25, 1951 and amendments), have petitioned the Minister of Labour to submit certain amendments to the said decree to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council; Whereab the petition was published in the Quebec Official Gazette of July 10, 1965; WHEREAS no objection was raised against the approval of the proposed amendments; It IS ORDAINED therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Laboui : That said decree number 94 be amended bs follows: 1.The list of contracting parties of the first part is replaced by the following: \"Brown & Hyan Limited; (\"ullen Stevedoring Co.Limited; Eastern Canada Stevedoring (1963) Limited; Empire Stevedoring Co.Limited: North American Elevators Limited; The Montreal Ship Lining Go.Limited; Wolfe Stevedores Limited; Sorel Dock & Stevedoring Co.Limited.\" 2.Sections I to XIX arc superseded by the following: Section I.Definitions: (a) The word \"longshoreman\" designates any person engaged in the manual phase of loading and unloading ships.(6) The term \"car handler\" designates any person engaged in the manual phase of loading and unloading railway cars other than grain cars.(c) The word \"checker\" designates any person whose work consists of tallying cargo or performing clerical work for ships.(6) The word \"cooper\" designates any person engaged in the repair of cargoes.Section II.Jurisdictions: (a) Industrial juration: This decree covers the loading and unloading of all inland, coastal and ocean-going vessels; the loading and unloading of railway cars; the loading ami unloading of trucks for shipping lines; work performed by checkers and coopers in Sorel Harbour, as defined in this decree.(/;) Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction of this decree encompasses all of Sorel Harbour as defined by a Federal Government Order in Council dated February 22, 1933.Section 111.Wages: (a) Loading of grain: The wage rates for the loading of grain for 1965, 1966 and 1967 are those listed in subsections 1 of Appendix \"A\", \"B\" and \"C\" respectively.(6) Unloading of grain: For the unloading of grain from vessels operating on the Great Lakes and the ocean, into elevators, wage rates for 1965, 1966 and 1967 are those listes in subsections 2 of Appendix \"A\", \"B\" and \"C\" respectively.(c) Loading and unloading of certain cargoes: For the loading and unloading of vessels and/or 5486 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre 1965.97e année, No k2 nient, le déchargement et le nettoyage des navires et wagons de soufre, de cargos d'huile, kaolin, potasse, cyanamide, bois creosotes, bitume, superphosphate et autres cargaisons «lu genre, apparaissent au paragraphe 3° de l'annexe « A » pour 196\"), de l'annexe « B » pour 1966 et de l'annexe « C » pour 1967.d) Chargement et déchargement des autres cargaisons: Les taux de salaires pour le chargement et le déchargement «les cargaisons dont il n'est pai fait «le mention spéciale, dans les navires et les wagons, pour le nettoyage, le charbonnage et le montage d'appareils «le toutes sortes, apparaissent au paragraphe 4° de l'annexe « A 1 pour 196\"), de l'annexe « B » pour 1966 et de l'annexe « C pour 1967.e) Manipulation des explosifs: Les taux de salaires et les horaires de travail pour la manipulation des explosifs sont ceux qui apparaissent au paragraphe 6° «le l'annexe « A » pour 1965.«le l'annexe « B \u2022 pour 1066 et de l'annexe « C \u2022 pour 1067./) PoriêW d'eau: Le taux «le rémunération du porteur «l'eau sera celui qui est indiqué au paragraphe 5° de l'annexe « A » pour 1965, de l'annexe « B ¦ pour 1966 et de l'annexe « C » pour 1967.Article IV.Semaine de travail et bulletin de paie: La semaine «le travail (pli sert à établir le paiement «lu salaire s'étend du samedi soir à minuit au samedi suivant à minuit.L'employeur «loit payer ses ouvriers pour ladite semaine de travail avant 11 h du matin le jeudi de la semaine suivante.IjC.s mentions suivantes doivent apparaître sur l'enveloppe de paie, sur le chèque ou sur le bulletin «le paie distinct: le nom de l'employeur, les noms et prénoms du salarié, le matricule du salarié, l'emploi occupé par le salarié, la date «lu paiement et les périodes de travail of Appendix \"A\", \"B\" ami \"(\"' respectively.Section 11'.Work week and earnings statement: The work week Used as a basis for the payment of wages runs from midnight Saturday to tlu-following midnight Saturday.Employers shall pay their employees for the said work week before 11:00 a.m.on Thursday of the following week.The following particulars should be listed on the pay envelope, cheque or separate earnings statement : employer's name.employee's name in full, employee number.employee's occupation, payment date and work periods corresponding thereto, number of regular hours, number of overtime hours, hourly wage rate.gross amount of wages, type and amount of deductions made, net take-home pay.Section V.Schedules: (a) Work begins at: 8:00 a.m., 1:00 p.m., and 7:00 p.m.Calls for 8:00 a.m.should be made before 5:00 p.m.on the previous day.Calls for 1:00 p.m.should l>c made before 10:00 a.m.on the same day.Calls for 7:00 p.m.should l>e made before 1:00 p.m.on the same day.(6) The above calling times do not apply to employees already at work or to men handling moorings.Employees already at work as well as those who receive a minimum may be called in to work for any time.(c) Longshoremen reporting in for such times as well as those requested to stay after such times shall be paid at the regular rate from that time until dismissed.Such employees shall receive the equivalent of two hours' pay at the regular rate for each call, regardless whether they work or are dismissed.Those who do not report in for work shall not be paid.In the event of adverse QUEBEC! OFFICIAL GAZETTE, October 16, 1965, Vol.97, No.5487 qu'lb soient renvoyés.Ladite indemnité ne sera pas payée à ceux qui ne se présentent pas au travail.Au cas de mauvaise température, il appartient aux olficiers du navire de décider s'il j a travail ou non./) la nuit, entre minuit et 1 h du matin Les débardeurs qui doivent travailler pendant les heures des repas doivent recevoir une majoration «le salaire de 100% «lu taux en vigueur pour l'heure «lu repas et chaque heure suivante jusqu'à ce qu'ils soient libérés pour prendre leur repas.Article VII.Heures supplémentaires: Tout travail exécuté à compter «le 5 h de l'après-mitli «ntraine une majoration de 50% du taux de salaire en vigueur.Tout travail exécuté après i\\ Ii du soir entraîne une majoration de 100% du taux de salaire en vigueur.Article I'll I.Appela: L'employeur doit appeler au travail les ouvriers dont il a besoin pour 8 h du matin et 1 h de l'après-midi et les rémunérer conformément aux taux réglementaires à compter des heures ci-«lcssus jusqu'à ce qu'il les ait renvoyés ou mis au travail.Lesdits ouvriers ont 'huit à une indemnité minimale égale à deux heures de travail, qu'ils soient mis au travail ou non.irticle IX.Curantie de quatre heures de salaire: Toute équipe normale mise au travail recevra une indemnité minimale égale à quatre heures au taux en vigueur.Cependant, dans les cas où le présent décret contient une autre disposition à ee sujet ou que le travail est interrompu pour cause «le mauvaise température ou qu'il s'agit m- construction «le cloisons ou de plate-formes, la garantie minimale de «leux heures s'applique.I.indemnité de quatre heures établie ci-dessus ne s'applique qu'au premier appel sur chaque n.'vire.Article X.Ouvrier supplémentaire: Tout ouvrier supplémentaire appelé durant une période de travail doit être rémunéré à compter de l'heure où l'équipe a commencé de travailler jusqu'à l'heure où la«lite équipe est renvoyée ou jusqu'à la (in «le la période de travail.Si l'employeur ne requiert pas les services «l'un ouvrier supplémentaire pour toute période mentionnée plus haut, il peut le rechanger d'équipe.Cependant, la rémunération, ne doit pas être interrompue et le temps de travail court pendant l'heure du dtner et jusqu'à ce que le débardeur revienne à terre.Article XI.Contremaître: Les employeurs désignent les contremaîtres et ils ont le droit de les renvoyer et de leur désigner des remplaçants s'ils ne sont pas satisfaits d'eux.Un contremaître renvoyé ou démis de ses fonctions a le droit de soumettre son cas au comité paritaire.weather conditions, the ship's officers shall decide if there is to be work or not.(d) No longshoreman may be forced to report in for work between 7:00 p.m.and 8:00 a.m.(e) Four (4) men constitute a regular gang for trimming bunker-coal.Men so employe*! shall receive a minimum of four (4) hours' pay at the prevailing rate.(/) An employer is not compelletl to pay the above-mentioned minimum when an insutficient number of men report for work and when they, refuse to work.Section VI.Meal times: Meal times are as follows: (a) Breakfast: 6:00 a.m.to 8:00 a.m.(b) Dinner: Noon to 1:00 p.m.(c) Supper: 6:00 p.m.to 7:00 p.m.(d) Night shift: Midnight to 1:00 a.m.Longshoremen who are required to work during meal time shall lie paid at double the prevailing rate for for this hour and for every subsequent hour until they are sent back for their meal.Section VII.Overtime: All work done after 5:00 p.m.shall Be paid at time and a half.All work done after 6:00 p.m.shall be paid at double time.Section VIII.Calls: The employer shall call in to work all the workmen needed for 8:00 a.m.and 1:00 p.m.He shall pay them at the stipulated rate from these times until they are dismissed or put to work.Such workmen are entitled to a minimum equal to two hours' pay, whether they be put to work or not.Section IX.Four hours' pay guarantee: Any regular shift which is put to work shall receive a minimum of four hours' pay at the regular rate.However, the two hours' guarantee applies: in the case where this decree contains another provision in this connection; when work is interrupted because of bad weather; whenever platforms or partitions are being built.The four hours' pay applies only for the first call on each ship.Section X.Extra xcorker: Any extra worker called in during a work period shall be paid from the time the shift began work until the time such shift is dismissed or until the end of the work period.Should the employer not require the services of an extra worker for the entire above-mentioned period, he may change him to another shift.However, payment shall not be interrupted and the working time runs through the dinner hour up to the time the longshoreman returns ashore.Section XI.Foreman: Employers appoint foremen and they may dismiss or replace them, should they prove unsatisfactory.A h du matin les dimanches, le jour de l'Ascension et le jour de la Toussaint.d) Les heures de repas pendent les jours fériés doivent être les mêmes qu'aux jours ordinaires.e) Si un ouvrier est appelé au travail un «les sept jours fériés mentionnés ci-haut ou le dimanche et qu'on ne le met pas au travail, il a droit, pour chaque appel, à une indemnité égale à deux heures de salaire au taux en vigueur./) Les appela pour les heures mentionnées à l'article Y, pour le dimanche et les jours fériés doivent être faits avant ô h de l'après-midi le jour précédent, sauf lorsque les ouvriers sont au travail après 5 h de l'uprès-midi le jour précédent et qu'ils reçoivent l'appel avant de quitter le travail.Les ouvriers appelés pour toute lumre les dimanches et les jours fériés, peuvent être rappelés pour une heure subséquente le même jour.Cependant, la présente disposition ne s'applique pas aux ouvriers qui font l'amarrage d'un navire et l'employeur peut les appeler en tout temps aux heures mentionnées à l'article Y.Article XIV.Indemnité de congés payés: L'employeur doit accorder à tous les débardeurs qui ont été à son service pendant la sniaon de navigation line indemnité de congés payés calculée à partir du salaire total que chacun a reçu pendant ladite saison.L'indemnité de congés sera de 4% pour ceux qui ont moins de cinq années de service comme débardeurs, et de 5% pour ceux qui ont cinq années et plus de service.Le paiement de ladite indemnité se fera quinze jours après la fin de la saison ou avant le 30 décembre de chaque année.Article XV.Conditions de travail: 1) Le Comité paritaire a le droit de nommer un représentant qui aura accès à tous les docks, hangars ou navires dans ou sur lesquels travaillent Tes ouvriers afin de surveiller la mise à exécution du présent décret.2) Tous les contremaîtres et les ouvriers sont sous la direction du représentant des compagnies ou des entrepreneurs d'arrimage, mais les ouvriers doivent recevoir les ordres par l'entremise de leurs contremaîtres respectifs.Ces derniers choisissent leurs ouvriers.3) Tout ouvrier qui fume dans la cale, vole ou est sous l'empire de l'alcool au travail peut être renvoyé en tout temps.Foremen shall receive 20«j un hour above the minimum wage rates.Section XII.Fractional time unit: Work schedules shall l>e set up according to the time officially recognized in the city of Sorel (Eastern Standard or Daylight Saving).The quurter-hour is the basic fractional time unit.Should employees or shift workmen s/ork beyond one-quarter, one-half or three-quarters of an hour, they shall be paid for the entire quarter-hour.Section XIII.Holidays: (a) In compliance with the provisions of the preceding subsections, double time shall be paid for all work performed on: Sunday, Saint John the Baptist Day.Labour Day, Canada Day.Ascension Day.All Saints' Day, Thanksgiving Day and Good Friday.(b) If the celebration of the aforesaid holidays is postponed by law, decree or by agreement between the parties, the other designated day shall Ih* considered as the holiday for the purp sei of this section.(c) Longshoremen shall not be compelled to report for work before (.1:()0 a.m.on Sundays, Ascension Day and All Saints' Day.( 5489 4) On doit enlever ou boulonner les baux des -outilles lorsque les ouvriers travaillent dans la cale et utilisent un treuil.,'>) Les compagnies ou les entrepreneurs d'arrimage ont le droit de décider de la distribution des ouvriers d'une équipe, de l'usage de garants .Kcouplés, ainsi que de l'emploi de toute autre u t'thode sure et pratique de chargement et de déchargement.6) a) Dix-huit (18) ouvriers et un (1) contremaître constituent une équipe normale pour arrimage ou lu mise en sac des cargaisons de grain.b) Quand on urrime le grain uux moyens d'ar-rimeurs mécaniques, on doit utiliser au moins neuf (9) ouvriers et un (1) contremaître pour un arrimeur mécanique, dix-huit (18) ouvriers et deux (2) contremaîtres pour «Jeux (2) arrimeurs mécaniques, vingt-sept (27) ouvriers et trois (3) i ontremaîtres pour trois (3) arrimeurs mécaniques 11 trente-six (30) ouvriers et quatre (4) contremaîtres pour quatre (4) arrimeurs mécaniques.c) Les ouvriers (pli sont en dis|>onihilité pour chaque arrimeur mécanique à grain ne devront pas être employés à un autre travail pendant que l'arrimeur est en marche.d) Quand on utilisera un arrimeur mécanique, ou devra employer un (1) ouvrier sur le quai pour prendre soin des conduits électriques.S'il y a plus d'un arrimeur mécanique, il devra y avoir deux (2) ouvriers à cette fonction.e) Si l'on procède au chargement du grain au moyen de conduit seulement, on emploiera deux (2) ouvriers par conduit.U y aura un (1) contremaître jxnir les ouvriers aux conduits pour le chargement du grain./) Sarire-citerne: i.Pour le chargement du grain à bord d'un navire-citerne au moyen de conduit, il y aura deux (2) ouvriers par conduit «t un (1 ) contremaître: ii.Si le chargement du grain requiert du gréement, on devra employer en plus neuf (9) ouvriers et un (1 ) contremaître pour l'appareillage îles gréementa; ces ouvriers devront être appelés au travail en même temps que les préposés aux conduits; iii.Dans tous les cas où il se fera de l'arrimage manuel, on devra employer seize (16) ouvriers et un (1) contremaître.g) On doit employer deux (2) ouvriers par conduit et un (1) contremaître pour tous jes ouvriers aux conduits.Toutefois, s'il est nécessaire le déplacer les conduits, la compagnie ou son représentant jxnirra appeler deux (2) ouvriers supplémentaires par conduit.7) Treize (13) ouvriers et un (1) contremaître constituent une équipé normale pour l'arrimage «les cargaisons en vrac à l'exception du travail BUr les péniches à charbon qui nécessite au i oins huit (8) ouvriers et un (1) contremaître.Toutefois, lorsque le déchargement se fait au moyen des treuils d'un navire avec tunnel dans la cale, il doit y avoir un surveillant de chaque côté où s'effectue le déchargement.8) Une équipe normale pour l'arrimage du manganèse et pour l'utilisation d'une pelle mécanique est composée de huit (8) ouvriers et d'un (1) contremaître.9) Une équipe normale pour l'arrimage du manganèse et pour l'utilisation de deux pelles mécaniques est composée de seize (16) ouvriers t d'un (1) contremaître.10) On doit emplyer quatorze (14) ouvriers et un (1) contremaître sur chaque navire pour le léehargement des cargaisons mentionnées à (4) Hatch beams shall be removed or bolted whenever men are working in the hold and are using a winch.(5) Companies or contracting stevedores may decide how workmen in a gang are to lx* distributed, how coupled falls or any other safe and practical unloading or loading method are to Ik* used.(6) (a) Eighteen (18) workmen and one (1) foremen constitutes a regular gang for the trimming and bagging of grain cargoes.(6) When a mechanical trimmer is used for trimming grain, the following men should work: nine (9) workmen and one (1) foreman for one mechanical trimmer; eighteen (18) workmen and two (2) foremen for two (2) mechanical trimmers; twenty-seven (27) workmen and three (3) foremen for three (3) mechanical trimmers and thirty-six (36) workmen and four (4) foremen for (4) mechanical trimmers.(c) Workmen assigned to each mechanical trimmer shall not be engaged in other work while the trimmer is operating.(d) When a mechanical trimmer is used, one (1) workman on the wharf shall look after the electrical cables.Whenever there is more than one mechanical trimmer, two (2) workmen should lie assigned to this work.(e) When running grain only, two (2) men per pipe shall be used.One (1) foreman shall be assigned to the men at the pipes.(/) Tankers: i.For the loading of grain on to a tander by means of pipes, there shall be two (2) men per pipe and one (1 ) foreman.ii.Should the loading of grain require loading gear, nine (9) more workmen and one ( 1 ) foreman are required to set up such gear.These workmen shall la?called to work at the same time as those working on pipes.iii.Whenever trimming is done manually, sixteen (16) workmen and one (1) foreman shall be employed.(g) For all workmen on pipes, two (2) workmen per pipe and one (1) foreman shall l>e used.However, should it be necessary to move pipes, the company or its representarive may call two (2) extra workmen per pipe.(7) Thirteen (13) workmen and one (1) foreman constitutes a regular gang for the trimming of bulk cargoes with the exception of coal barges which require at least eight (8) workmen and one (1) foreman.However, whenever unloading is done by means of winches of a ship with a tunnel in the hold, there should be a watchman on each side being unloaded.(8) A regular gang for the trimming of manganese and the operation of a mechanical shovel shall consist of eight (8) workmen and one (1) foreman.(9) A regular gang for the trimming of manganese and the operation of two mechanical shovels shall consist of sixteen (16) workmen and one (1) foreman.(10) Fourteen (14) workmen and one (1) foreman shall l>e used on each vessel for the unloading of cargoes mentioned in section III.Such 6400 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 1G octobre 19G5, 97' année, No U l'article III.Ces ouvrier! seront appelée dès qu'il sera possible «le les mettre au travail.Les ouvriers affectés à ee travail ne seront pas divisés.11; On doit employer un porteur d'eau quand des ouvriers travaillent à la manipulation de toute cargaison, y compris le chargement ou le déchargement du grain.12) Si les débardeurs doivent décharger du grain d'un navire océanique, il doit y avoir au moins quatre (4) ouvriers en plus d'un contremaître.13) Ou doit employer quatre (4) ouvriers et un (1) contremaître sur chaque chaland transportant différents produite.Ces ouvriers seront appelés dès qu'il sera possible «le les mettre au travail.14) Les employeurs ont le droit «l'augmenter le nombre d'ouvriers «l'une équi|je au l>esoin.15) L'employeur premlra les mesures possibles pour éviter les déplacements anormaux «le poussière.16) [^'employeur doit mettre à la «lisj>ositi«>n «le ses ouvriers des lieux «l'aisaïU'e à proximité «les lieux «le travail et les maintenir propres.17) Pour le déchargement «les bateaux «le grain des lacs (chalands), les débardeurs seront rémunérés «!«\u2022 la façon suivante: La rémunération qui «luit être payée p«>ur le déchargement «les bateaux «le grain «les la«\\s, est déterminés par la quantité «le grain ù décharger «!«\u2022 chaque navire, conformément à la table suivante: a) Pour toute cargais«m «le 100.000 boisseaux et moins, une rémunération minimale égale à cinq (5) heures «le travail et une (1) heure additionnelle par 20.000 boisseaux, jusqu'à concurrence «le 160.000 Innsseaux.b) Pour toute cargaistui de 160,000 boisseaux et plus, une heure «le r«''munérati«>n par 20.000 boisseaux pour les premiers 300,000 lioisseuux de la cargaison avec une garantie minimale de huit (S) heures «le rémunérâti«>n par cargaison.c) Une (1) heure a«l«litionn«'lle de rémunération par 25.000 Imissenux pour la surplus de 300.000 l>oisseaux «l'une cargaison et jusqu'à concurrence «le 600,000 b< iss«-aux.d) Une (1) heure additionnelle de rémunération par 30.000 boisseaux pour le surplus de 600.01.0 boisseaux dans une même cargaison.La rémunération ci-dessus prévue est payable au taux normal.Les majorations pour heures supplémentaires ne s'appliquent qu'aux heures ou les débardeurs sont effectivement au travail en dehors des heures normales de travail fixées dans le présent décret.Il n'y a aucune majoration pour heures supplémentaires pour les heures OÙ le déchargement de la cargaison se fait mécaniquement.Quand on procède au déchargement de la cargaison au moyen «l'une jante marine, on emploie douze (12) ouvriers, un contremaître et un porteur d'eau.Quan«l OU procède au déchargement de la cargaison au moyen de deux (2) jantes marines, on emploie vingt-quatre (24) ouvriers, deux contremaîtres et un porteur «l'eau.Les taux «le la rémunération ci-dessus prévue sont ceux cpii apparaissent au paragraphe 5° de l'annexe « A » pour 1965, de l'annexe « B » pour 1966 et de l'annexe « (' » pour 1967.18) L'employeur s'engage, surtout s'il s'agit d'une cargaison de soufre, à installer sur les workmen shall be called as soon as they can be put to work.Workmen so employed shall not be divided.(U) A water boy shall be employed for the handling of any cargo, including the loading and unloading of grain.(12) Should longshoremen l>e required to Unload grain from an ocean vessel, there shall Ik?at least four (4) workmen besides a foreman.(13) Pour (4) workmen and one (I) foreman shall Ik* employed on each barge carrying various products.Such workmen shall be called as soon as they can be put t«> work.(14) Employers may increase the number of workmen in a gang as required.(15) Employers shall take all necessary steps to avoid excessive raising of dust.(16) Employers shall provide washrooms for employees close t«» the working area, and lie shall keep these clean.(17) Longshoremen shall be paid as follows for unloading Great Lakes grain vessels (barges : Payment for unloading Great Lakes vessels is based on the amount of grain to be unlos led from each vessel, according t«» the following table: (a) For cargoes of 100*000 bushels or less ¦ 5-hour minimum ami one (1) extra hour for eacli 20.000 bushels, up t«> 160,000 bushels.(/>) Pol cargoes ol 160,000 bushels «>r more: one hour's pay for every 20,000 bushels «»f tla-cargo's first 300,000 bushels, with a guaranteed minimum «>f eight (S) hours' pay per cargo.(c) An extra hour's pay for each 25.000 bushels over 300.000 bushels, up to a maximum of 600.000 bushels.(d) An extra hour's pay for each 30.000 bushels over 600,000 bushels in a same cargo.The aVOVC is paid at straight time.Overtime rates apply only t«> hours worked by longshoremen outside the standard writing hours stipulated in this decree.No overtime is paid for extra hours unloading cargo mechanically.When cargoes are unloaded by means of one (1) leg, twelve (12) men, one foreman and one water boy are employed.When cargoes are unloaded by means of two (2) legs, twenty-four (24) men, two foremen and one water boy are employed.The above-mentioned rates are those listed in subsections 5 of Appendix \"A\", \"B\" and \"C\" for 1965, 1966 and 1967 respectively.(18) Employers agree, especially in the case of sulphur cargoes, to install a water pump on QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 10, 1905, Vol.97, No.Itf 5491 lii iix de travail une pompe ù euu en eus d'incendie.Il s'engage également ù prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer lu plus grande -, «mité «les travailleurs.19) L'ouvrier qui travaille sur un navire dont la cargaison est en feu, a droit à une majoration île salaire de 100%.La présente disposition s'applique seulement aux cales all'ectées par le feu, la fumée, la vapeur OU le gaz.Si l'ouvrier fait la manutention «l'une cargaison submergée dans une cale, il a droit à une majoration de salaire de 100% pour ce travail.20) Pour le chargement ou le déchargement d'un navire sans l'aide d'équipement mécanique, mais avec le treuil du navire, l'équipe minimale géra de seize (10) ouvriers et d'un (1) contremaître.21) Pour le chargement ou le déchargement d'un navire à l'aide d'un chariot élévateur sur le quai et dans l'écoutille on emploiera treize (13) ouvriers, y compris les conducteurs et le contremaître.Quand on chargera le centre de l'écoutille et qu'on utilisera un chariot élévateur, on emploiera treize (13) ouvriers et un (1) contremaître, avec un chariot élévateur sur le quai.\\a-iiombre d'ouvriers employés dans une équipe au début «lu travail doit demeurer le même jusqu'à la tin de la période de travail.22) La charge «le l'élingue ne doit en aucun cas dépasser les limites «le sécurité et doit être soumise à l'inspection des gardiens «lu port et du capitaine du navire.23) Les ouvriers appelés au travail doivent se présenter ù l'embarcadère à l'heure du début du travail.Ceux qui se présentent habituellement au travail après les heures précises et qui quittent avant l'heure fixée ne seront rémunérés que pour les heures effectivement travaillées.24) Les ouvriers ne seront pas obligés de demeurer dans l'écoutille quand on utilisera un électro-aimant.Les signalcurs seront mis au l ravail au moment même où les grues mécaniques seront mises en marche.25) Toute mésentente quant à l'interprétation îles conditions de travail contenues dans le présent décret devra être soumise par le représentant «les débardeurs sur les quais au représentant «le l'employeur dans les trois (3) jours de sa naissance.Le représentant «le l'employeur rendra une réponse dans les six (0) jours ouvrables suivants: Aucun officiel «les.employeurs ou «les débar-deurs n'a le droit de faire quelque changement à l'horaire ou aux conditions de travail stipulés dans le présent décret.26) Les employeurs s'engagent à améliorer les moyens de transport des ouvriers travaillant aux «xplosifs, à leur fournir «les ceintures de sauvetage et un abri suffisamment grand et confortable pour prendre leur repas.27) Pour le chargement et le déchargement «les «¦xplosifs, l'équipe normale sera composée de vingt-deux ouvriers, d'un contremaître et «l'un porteur d'eau.Article XVI.Amarrage des navires: Il doit y avoir au moins cinq ouvriers et un contremaître pour l'amarrage d'un navire.Les préposés à l'amarrage des navires océaniques doivent recevoir une indemnité minimale égale à deux heures de salaire au taux en vigueur.Toutefois, s'ils sont «léjà au travail au moment de l'accostage des navires, ils n'ont pas «Iroit à l'indemnité susmentionnée.Il doit y avoir au moins huit ouvriers et un contremaître s'il faut traîner les amarrages afin the working area to l>c used in case of fire.They also agree to take all necessary steps to ensure the maximum safety of workers.(19) Workmen working on a ship with its cargo on fire are entitled to double time.This provisions applies only to holds damaged by fire, smoke steam or gas.Double time shall also be paid for work «Unie in hatches where the cargo is submerge«l.(20) For loading or unloading a vessel without mechanical equipment but with the ship's winch, there shall be at least sixteen (16) workmen ami one (1) foreman.(21) For loading or unloading a vessel with a fork-lift truck on the wharf and in the hatch, thirteen (13) workmen shall l>e employed, including the drivers an«l foreman.When the hatch's center is loaded an«l one fork-lift truck is use«l, thirteen (13) workmen ami one (1) foreman shall be employed, with one fork-lift truck on the wharf.The numl>cr of workemn employed in a shift at the beginning of a working period shall remain the same until the end of same.(22) The slingload shall never exceed safety limits and shall Ik.' subject to inspection by the harbour's watchmen and the ship's captain.(23) Workmen called to work sliall report at the gangway at starting time.Those who usually report to work after the given hours and leave before finishing time shall only Ik* pan! for hours actually worked.(24) Workmen are not required to remain in the hatch when an electro-magnet is being used.Hatch men shall lie put to work as soon as the crames are in operation.(25) Any misunderstanding as to the interpretation of the employment conditions of this decree sliall be submitted to the management's representative by the longshoremen's representative on the wharves within three (3) days.The management's representative shall supply an anwer within the following six (6) working days.No officer of employers or longshoremen has the authority to make any changes in the schedules or employment conditions stipulated in this decree.(26) Employers agree to improve transportation means for men handling explosives and to supply them with safety belts ami a reasonably spacious and comfortable shelter for meals.(27) For unloading and loading of explosives, a regular gang shall consist of twenty-two workmen, one foreman and one water boy.Section XVI.Mooring vessels: There must Ik* at least five workmen and one foreman for mooring a vessel.Men mooring ocean vessels shall recieve a minimum of two hours' pay at the prevailing rate.However, if the men are already at work when the vessels dock, they are not entitled to the ahovementioned pay.At least eight workmen and one foreman shall be employed when lines liave to Ik?displaced 5492 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 10 octobre 1965, 97' année, No Jf de déplacer le nuvin'sur une distance plus grande along th wharf to move the ship more than il, que sa longueur.Le déplacement d un navire length.Moving of a ship from one wliarf to d'un quaj à un autre e remitted to étant celle de la retraite, une somme égale aux each employee on the date fixed by the Pari I y montants déposés selon le paragraphe précédent.Committee as the retirement date, augmentée des intérêts courus moins les frais encourus par la compagnie de fiducie.La partie de deuxième part conservera un The party of the second part shall keep a relevé de ces sommes et elle le remettra gratui- record of all such amounts and shall remit same tement au fonds de fiducie ou aux employeurs without cliargc to the trust fund or to the em- afin (pie chaque salarié reçoive éventuellement plovers so that every employee may eventually la somme qui lui est due.receive the amount (lue him.Article XIX.Durée: l^c présent décret demeure Section XIX.Term: This decree remains in en vigueur jusqu'au 31 décembre 1967.U se force until December 31, 1967.It automatically renouvelle automatiquement pour une autre renews itself from year to year thereafter unless année à moins que l'une des parties n'avise one of the contracting parties advices the of lier l'autre par écrit de son intention de le modifier in writing that it intends to amend or rescind ou d'y mettre fin et ce.dans une période d'au same no more than sixty (60) and no less than plus 60 jours et d'au moins 30 jours avant le 31 thirty (30) days prior to December 31, 1967.décembre 1967.Article XX.Texte officiel: Le texte français est Section XX.Officiai version: The French ver- le texte original.Il demeure le texte officiel dans sion is the original.It remains the official text les cas où il y aurait conflit d'interprétation entrt should interpretation difficulties arise between le texte français et la version anglaise.the French and English versions.« Annexe « A » \u2014Appendice \"A\" Tableau des salaires \u2014 Wage scale (1965) Débardeurs \u2014 Longshoremen 1° Chargement du grain (Article III-« a ») 1.Loading of grain (Section III-\"a\") Entre minuit et midi: Entre midi et minuit: Midnight to noon: Noon to midnight: Minuit à I a.m.C a.m.S a.m.Midi à I p.m.ii p.m.(I p.m.f p,m Midnight to à-to à-to à midi noon to à-to à-to à-to àmin.1 a.m.fi a.m.S a.m.to noon 1 p.m.5 p.m.H p.m.7 p.m.to midnight Du lundi au ven-di incl.-Mon.Fri.incl.87.32 83.66 $7.32 82.44 84.88 82.44 83.66 87.32 83.6b Le samedi (normal)-Sat.(regular).7.32 3.66 7.32 3.66 7.32 3.66 3.66 7.32 3.66 Dimanche et jours fériés (exc.samedi) - Sunday and Holidays (exc.Saturday).14.64 7.32 14.64 4.88 9.76 4.88 7.32 14.64 7.32 Samedi (jour férié) -Sat.(Holiday).14.64 7.32 14.64 7.32 14.64 7.32 7.32 14.64 7.32 2° Déchargement du grain (Article III-« b») Du lundi au ven- 2.Unloading of grain (Section III-\"6\") dredi incl.-Mond.Friday incl.7.02 3.51 7.02 2.34 4.68 2.34 3.51 7.02 3.51 Le samedi (normal)-Sat.(regular).7.02 3.51 7.02 3.51 7.02 3.51 3.51 7.02 3.51 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 10, 1965, Vol.97, JVo.)& 5493 Entre minuit et midi: Entre midi et minuit: Midnight to noon: Noon to midnight: Minuit à 1 a.m.ft a.m.S a.m.Midi à I p.m.ii p.m.ti p.m.7 p.m.Midnight to à-to à-to à midi noon to à-to à-to à-to à miumt I a.m.f! a.m.H a.m.to noon t p.m.r, p.m.ft p.m.7 p.m.to midnight Dimancheset jours ('\u2022ries (exc.samedi) - Sunday d Holidays (exc.Saturday).$14.04 $7.02 $14.04 $4.68 10.86 $4.68 $7.02 $14.04 $7.02 Samedi (jour férié) _ Sat.(Holiday).14 04 7.02 14.04 7.02 14.04 7.02 7.02 14.04 7.02 3° Chargement et déchargement de certaines cargaisons (Article III-« c ») 3.Loading and unloading of certain cargoes (Section III-\"e\") Du lundi au vendredi incl.-Mon.Fri.incl.7.62 3.81 7.62 2.54 5.08 2.54 3.81 7.62 3.81 \\m samedi (nor- mal-Sat.(regular) 7.62 3.81 7.62 3.81 7.62 3.81 3.81 7.62 3.81 I >iinanche et jours fériés (exc.samedi) - Sundays and Holidays (exc._ \u201e\u201e Saturday).15.24 7.62 15.24 5.08 10.16 5.08 7.62 15.24 7.62 \u2022samedi (jour férié) _ M -Sat.(Holiday).15.24 7.62 15.24 7.62 15.24 7.62 7.62 15.24 7.62 4° Chargement et déchargement des autres cargaisons (Article III-« d ») 4.Loading and unloading of other cargoes (Section III-'W\") I Mi lundi au vendredi incl.-Mon.Fri.incl.7.17 3.58^ 7.17 2.39 4.78 2.39 3.58.H 7.17 3.58^ Le samedi (normal) -Sat.(regular).7.17 3.58^ 7.17 3.58M 7.17 3.58^ 3.58»^ 7.17 3.58»^ 1 M manche et jours fériés (exc.samedi)-Sundays and Holidays (exc.Saturday).14.34 7.17 14.34 4.78 9.56 4.78 7.17 14.34 7.17 Samedi (jour férié) _ .\u201e -Sat.(Holiday).14.34 7.17 14.34 7.17 14.34 7.17 7.17 14.34 7.17 5° Porteur d'eau \u2014 Dans tous les cas (Article HI-«/ ») 5.Water boy \u2014 In ail instances (Section ni-\"/\") Du lundi au vendredi incl.-Mon.y Fri.incl.6.87 3.43^ 6.87 2.29 4.58 2.29 3.43H 0.87 3.43^ Le samedi (normal)-Sat.(regu- , ~ .îar).6.87 3.43^ 6.87 3.43H 6.87 3.43H 3.43^ 6.87 3.43^ Dimanche et jours fériés (exc.samedi)-Syndays and Holidays (exc.Saturday).13.74 6.87 13.74 4.58 9.16 4.58 6.87 13.74 6.87 Samedi (jour férié)___ -Sat.(Holiday).13.74 6.87 13.74 6.87 13.74 6.87 6.87 13.74 6.87 6° Manipulation des explosifs (Article III-« e » ) 6.Handling of explosives (Section III-V) De-From De-From De-From I)e-From Apres S a.m.midi à 1 a.m.n p.m.ti p.m.à midi noon to à-to à-to Alter to noon 1 p.m.ô p.m.(I p.m.6 p.m.Débardeur \u2014Longshoreman.$2.71 $5.42 $2.71 $4.06H$8.13 Porteur d'eau \u2014 Water Bov.2.71 5.42 2.71 4.06^ 8.13 (ontremattre-r Foreman.!.2.91 5.82 2.91 \u2022 4.36H 8.73 < liarpentier \u2014 Carpenter.2.81 5.62 2.81 4.21H 8.43 (ontremattre supérieur \u2014 Walking Boss.3.31 6.62 3.31 4.96^ 9.93 Conducteur de treuil et surveillant d'écoutilles \u2014 Winchoperatorand hatch attendant.2.81 5.62 2.81 4.21^ 8.43 5494 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre 1966, 97' année, No 42 Annexk « B » \u2014Appendix \"B\" Tableau des salaires \u2014 Wages scale (1960) Débardeurs \u2014 Longshoremen 1° Chargement de gram (Article III-« a ») 1.Loading of grain (Section III-\"a\") Entre minuit et midi: Entre midi et minuit: M idnight to noon: Noon to midnight: Minuit à la.m.C a.m.8 a.m.Midi à lp.m.ii p.m.H p.m.Midnight to à-to à-to à midi noon to à-to à-to à-to 1 a.m.il a.m.S a.m.to noon I p.m.fi p.m.U p.m.7 p.m.Du lundi au vendredi incl.-Mon.Fri.incl.«7.62 $3.81 $7.62 $2.54 85.08 $2.54 $3.81 $7.62 $3.81 Le samedi (normal) - Sat.(regular).7.62 3.81 7.62 3.81 7.62 3.81 3.81 7.62 3.81 Dimanche et jours fériés (exc.samedi) - Sunday and Holidays (exc.Saturday).15 24 7.62 15.24 5.08 10.15 5.08 7.62 15 24 7.62 Samedi (jour férié) -Sat.(Holiday).15.24 7.62 15.24 7.62 15.24 7 62 7.62 15.24 7.62 2° Déchargement du grain (Article IH-« b ») 2.Unloading of grain (Section III-\"6\") Du lundi au vendredi incl.-Mon.Fri.incl.7.32 3.66 7.32 2.44 4.88 2.44 3.66 7.32 Le samedi (normal)-Sat.(regular).7.32 3.66 7.32 3.66 7.32 3.66 3.66 7,32 Dimanche et jours fériés (exc.samedi) - Sunday and Holidays (exc.Saturday).14.64 7.32 14.34 4.88 9.76 4.88 7 32 14.64 Samedi (jour férié) -Sat.(Holiday).14.64 .7.32 14.64 7.32 14.64 7.32 7.32 14.64 3° Chargement et déchargement de certaines cargaisons (Article III-« c ») 3.Loading and unloading of certain cargoes (Section III-V) Du lundi au vendredi incl.-Mon.Fri.incl.7.92 3.96 7.92 2.64 5.28 2.64 3.96 7.92 3.96 Le samedi (normal) - Sat.(regular).7.92 3.96 7.92 3.95 7.92 3.96 3.96 7.92 3.96 Dimanche et jours -fériés (exc* samedi) - Sunday and Holidays (exc.Saturday).15.84 7.92 15.84 5.28 10.56 5.28 7.92 15.84 7.92 Samedi (jour férié) -Sat.(Holiday).15.84 7.92 15.84 7.92 15.84 7.92 7.92 15.84 7.92 4° Chargement et déchargement des autres cargaisons (Article HI-« d ») 4.Loading and unloading of other cargoes (Section lH-\"d\") Du lundi au vendredi incl.-Mon.Fri.incl.7.47 3.73^ 7.47 2.49 4.98 2.49 3.73^ 7.47 3.73'j Le samedi (normal) - Sat.(regular).7.47 3.73H 7.47 3.73» p.m.«»' p.m.7 p.m.to midniolit Du lundi au vendredi incl.- Mon.Fri.incl.|8.2K $4 14 88 .38 «2.76 «5 52 $2.76 $4.11 $H.28 $411 \\aï samedi (normal) - Sat.(regular).8.26 4 14 s.2s 4.14 8.38 4 14 4.14 8.98 4 M Dimanche et jours fériés (eXC.samedi) - Sundays and Holidays (exc.Saturday).16.56 8.38 16.56 5.52 11.04 5.52 8.28 10.56 8.28 Samedi (jour férié) -Sat.(Holiday) 16.56 8.38 16.66 8.28 16.66 8.28 8 28 16.56 8.28 4° Chargement et déchargement «les autres cargaisons (Article Hl-« d ») 4.Loading and unloading of other cargoes (Scetmn III-\" 8 a.m.midi à 1 a.m.ï p.m.tl p.m.à midi noon to à-to à-to Afiei to noon I p.m.ô p.m.U p.m.G p.m Débardeur \u2014 longshoremen.«2.93 $5.86 83.93 $4 39) 2 $8 79 Porteur d'eau \u2014 Water Bov.2.93 5.86 2.93 4.39»/2 8 70 Contremaître \u2014 Foreman.3.13 6.26 3.13 4.69» 2 9.30 Charpentier \u2014Carpenter.3.03 6.06 3.03 4 54»2 9.09 Contremaître supérieur \u2014 Walking Boss.3.53 7.06 8.58 5.29»2 10.59 Conducteur de treuils et surveillant d'écoutilles \u2014 Winch operators and hatch attendants.3.03 6.06 3.03 4.54»2 9.09 Le Greffier du Conseil Exécutif, Jacques PrImont, 12471-o Jacques Premont.12471-o Clerk of the Executive Council. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, 1968, Vol.97, No.& 5497 Ministère du Travail Avis de modification Commerce détail - Chicoutimi L'honorable Carrier Fortin, ministre du Tra-\\ail.donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus «le Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), «le toll intention «le soumettre à l'appréciation et à la «léeisiou «lu l.ienteiiant-(iouverneur en conseil, les modifica-lions suivantes au r«l rl un rayon «le cinq (5) milles «le leurs limites, à l'exception «le la cité d'Arvi«la: 1° L'Association professêonneue «les Marchands détaillants «le Chicoutimi sera radiée comme parlie contractante de première part.2° Toutes les dispositions «lu décret concernant les établissements commerciaux autres que ceux de l'alimentation au détail cesseront d'être en vigueur.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en ooneeil peut rendra obligatoires oss dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en ooneeil ne peut entrer en vigueur avant la date «le sa publication dans la Gazette officielle de Quittée, Durant les trente jours à compter «le la date de publication «le cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre «lu Travail recevra les objections, en double copie si possible, que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, (ïkkaki) Tremblay.Ministère «lu Travail, Quél>ec, le 16 octobre 1965.12471-0 \\\\ is de modification Employés de garages \u2014 Granby L'honorable Carrier Fortin, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), qu'à la suite d'une requête transmise par l«' Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est il se propose de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil la modification suivante au décret numéro 701 du 8 avril 1964 et amendement, relatif aux salariés de garages dans la cité de Granby et un rayon de dix milles de ses limites; Les paragraphes «/» et «i» de l'article I seront remplacés par les suivants: « f) Salarié: Le mot « salarié » désigne tout apprenti, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, tout manoeuvre ou ouvrier non qualifié, iout préposé aux pièces de rechange ou toute personne qui travaille individuellement, en équi-l>c ou en société.» < t) Poste d'essence: Le terme < poste d'essence; » désigne tout endroit fixe ou mobile où se lait exclusivement la vente d'essence ou de lubrifiants pour l'usage des véhicules à moteur, que ledit endroit soit exploité par un propriétaire ou un locataire comme établissement principal ou comme annexe d'un établissement principal.» Department of Labour Notice of amendment Retail Trade Chicoutimi Pursuant to the provisions «if the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 ami amendments), the Honourable Carrier Fortin.Minister f the Lieutenant-Governor in Council: 1.L*Association professionnelle des Marchands détaillants de ( hicoutimi is deleted as contracting party «>f the first part.2.All provisions of the decree «lealing with commercial establishments other than those «>f the retail food trade will no longer 1m> in force.Publication of this notice docs not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can l>e made binding only by an Order in Council, which comes into force on the «late «>f its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the honourable Minister of Labour will consider objections which interested parties may wish to make; objections should be submitted in duplicate if possible.(ii';hai«i> Tbbmblay, Deputy Minister of Labour.Department «>f Labour, Quebec, October 16.1965.12471-0 Notice of amendment Garage employees \u2014 Granby Pursuant to the privisions of the Collective Agreement Act (lt.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), the Honourable Carrier Fortin, Minister of Labour, hereby gives nofice that, as a result of a petition transmitted by the Joint Committee of the Automobile Industry of the Eastern Townships, he intends submitting the following amendment to decree number 701 of April 8,1964 and amendments (Garage employees in the city of Granby and a radius of ten miles from its limits) to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council : Subsections \"/\" and \"i\" of section I will be superseded by the following: \"(/) Employee: The word \"employee\" designates any apprentice, qualified workman or journeyman, artisan, labourer or unskilled labourer, spare parts man or any person working alone, in a team or in partnership.\" \"(i) Gasoline station: The term \"gasoline station\" designates any mobile or stationary place where only motor vehicle gasolines and lubricants are sold, whether this place be operated by a proprietor or lessee as a main concern or as an acessory thereto.\" 6498 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 10 octobre 1905, 97' année.No 42 La publication de présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Quéltec.Durant les trente jours à compter «le la date «le publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre «lu Travail recevra les objections, en coublc copie si possible, «pie les intéressés pourront «lésircr formuler.Le Sous-ministre du Travail, Gbbabd Tkkmblay.Ministère «lu Travail, Quélajc, le 10 octobre I960.13471-0 Vvis de modification Salariée de tarage» Sherbrooke L'honorable Carrier Fortin, ministre «lu Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions «le la Loi «le la convention collective (S.R.Q.1941.chapitre 163 et amendements), qu'à la suite d'Une requête transmise par le ('«\u2022mité paritaire «le l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est il se propose de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les mo«liHcations suivantes au décret numéro 1687 «lu 26 août 1001, relatif aux employée «h* garage dans la région de Sherbrooke: 1° Les paragraphes « a », « e », « g , « n » et « / » «le l'article I seront remplacés par les suivants: « a) Artisan: Ia' mot « artisan désigne toute toute personne faisant seule ou en société un travail régi par le décret pour sou propre bénéfice.Il désigne aussi tout employeur ou employeur professionnel lorsqu'il fait pareil travail.« e) Prévoie au service: Le terme « préposé au service » désigne tout salarié, homme ou femme, qui vend de l'essence ou «les lubrifiants, graisse lave ou conduit les véhicules a moteur, fait le nettoyage ou le chauffage «le rétablissement, change ou répare les chambres à air OU les pneus, change les accumulateurs ou exécute «le petites réparations, sur les véhicules à moteur.» « g) Salarié: Le mot « salarié » désigne tout apprenti, ouvrier qualifié OU compagnon, artisan, tout manoeuvre ou ouvrier non qualifié, tout préposé aux pièces de rechange ou toute personne qui travaille individuellement, en équipe ou en société.» « m) Poète d'Essence: Ia- terme « poste d'es- senoe déeigne tout endroit fixe ou mobile où m fait exclusivement la vente «l'essence ou «le lubrifiants pour l'usage «les véhicules à moteur, que ledit endroit soit exploité par un propriétaire OU un locataire comme établissement principal ou comme annexe d'un établissement principal.« /) Pompiste: Le terme « pompiste » désigne tout salarié, homme OU femme, qui distribue «le l'essence «ni des lubrifiants dans un poste «l'es- sence.» 2° Le paragraphe « a » «le l'article XIII (Apprentissage) sera remplacé par le suivant: « a) Dès son entrée dans l'industrie assujettie au décret, l'apprenti doit s'enregistrer ail Comité paritaire, afin de rendre |x>ssihlc la compilation «les différents stages de son apprentissage et expérience.» 3° Le deuxième alinéa «lu paragraphe « / «le 'article XIII sera remplacé par le suivant : Publication of this notice does not make bind ing the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can be made binding only by an Order in Council, which comes into force on the date of its publication in the Quel-Official Gazette.During the thirty days following publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider objections which interested parties may wish to make; objections should )>c submitted in duplicate if possible.Gkhakd Tkkmblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour.Quebec, October 10, 1966.13471-0 Notice of amendment Garage employees \u2014 Sherbrooke Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (U.S.Q.1941.chapter 163 and amendments), the Honourable Carrier Fortin, Minister of Labour, hereby gives notice that, as a result «>f a petition transmitted by the .I«»iul Committee «>f the Automobile Industry of the Eastern Townships, he intends submitting the following amendments to decree number 1637 of August 26, 1964 (Oarage employees in the Sherbrooke region) to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council: 1.Subsections \"a\", \"e\".\"g\", \"n\" and \"t\" of artu'le I will be superseded by the following: \"a) Artisan: The word \"artisan\" designates any person who.alone or in partnership and on his own account, does any of the work governed by the decree.It also designates any employer or professional employer doing such work.\" \"e) Service man: The term \"service man designates any male «>r female employee who: sells gasoline and lubricants; greases, washes or drives motor vehicles; cleans or looks after the establishment's heating; changes or repairs inner tubes or tires: changes batteries or carries out minor motor vehicle repairs.\" \"g) Employee: The word \"employee\" designates any apprentice, qualified workman or journeyman, artisan, labourer or unskilled labourer, spare parts man or any person working alone, in a team or in partnership.\" \"n) Gasoline station: The term \"gasoline station\" designates any mobile or stationary place where only motor vehicle gasolines and lubricants are sold, whether this place be operated by a proprietor or lessee as a main concern or as an accessory thereto.\" \"*) Pumpman: The word \"pumpman\" desig-nates any male or female employee who dispenses gasoline or lubricants in a gasoline station.\" 2.Subsection \"a\" of section XIII (Apprentie» ship) will be replaced by the following: \"a) Upon entering the industry subject to the decree, the apprentice shall register with the Parity Committee so that the various stages of his apprenticeship and experience may lie recorded.\" 3.Paragraph 2, subsection \"/\" of article XIII will be replaced by the following: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Odder 16, 1965, Vol.97, No.4$ 5499 « Cette répartition «lu nombre d'apprentis doit n'entendre de tous les métiers qualifiés mis en bloc.Aucun employeur ne peut faire travailler iin apprenti seul et un apprenti ne peut travailler seul a l'exécution «le travaux de métiers.Il doit toujours être accompagné d'un ouvrier qualifié f the Automobile Industry of the Eastern Townships, he intends submitting the following amendments to decree number 1921 «>f October 7.1964 (Garage employees in the electoral «listrict «»f Arthabaska) to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council: 1.Subsections \"a\", \"/\" and \"///\" of article I will be superseded by the following: \"a) Artisan: The word \"artisan\" designates any person who, alone or in partnership ami on his own account, does any of the work governed by the decree.It also designates any employer or professional employer «loing such work.\" \"(f) Employee: The word \"employee\" designates any apprentice, qualified workman or journeyman, artisan, labourer or unskilled labourer, spare parts man or any person working alone, in a team or in partnership.\" \"(f») Gasoline station: The term \"gasoline station\" designates any mobile or stationary place where only motor vehicle gasolines and lubricants are sold, whether this place be operated by a proprietor or lessee as a main concern or as an accessory thereto.\" 2.Paragraph 2.subsection \"/\" of article XIII (Apprenticeship) will be replaced by the following: \"Such distribution «>f the number «>f apprentices shall cover all qualified trades as a whole.N«) employer may have an apprentice work alone and no apprentice may do trade work alone.He must always be accompanied by a qualified journeyman of his trade.\" Publication of this notice es not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can be made binding only by an Order in Council, which 5500 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre 1966, 97' année.So W L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Quéliec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans in Gazette officielle de Quéltec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections, en double copie si possible, que les intéressés pourront désirer formuler.Sous-ministre du Travail, Gruau» Tui:\\iulav.Ministère du Travail, Québec, le 1*} octobre 1965.12471-0 comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider objections which interested parties may wish to make; objections should be submitted in duplicate if possible. in Council number 1S45, dated September : >.1965, to appoint .Messrs.Roma Cousineau, of Verdun, André Casgrain, of Rimouski, Albert I,.Bissonnctte, Rupcr C.T.Harris, John Ewasew and (Jérald J.Ryan, the four latter of Montreal, all six advocates and members of the Bar of the Province, Queen's Counsel.Notice is hereby given that the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to make, by commission under the Great Seal of the Province, the following appointment: Quebec, September 15.1965.Air.Jacques Anctil, advocate and member of the Bar of the Province, of the city of Montreal: appointed, under the Courts of Justice Act (Revised Statutes, 1964, chapter 20), Judge of the Sessions, with jurisdiction in the entire province, but particularly and without restriction in the judicial district of Montreal, with residence in the city of -Montreal or the immediate vicinity; the said Mr.Jacques Anctil, in view of his present appointaient by the Lieutenant-Governor in Council as Judge of the Sessions, is authorized to exercise, under the authority of paragraph (b) of section 466 of the Criminal Code, from and after September 15.1965, the jurisdiction of a magistrate under Part XVI of said Criminal Code.(iiven at the office of the Provincial Secretary on October 13, 1965.R aymox d DorVILLK, 12409 Assistant Secretary of the Prorinn .Proclamation Canada, Province de PAIL COMTOIS Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef «lu Commonwealth.Défenseur tie la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, \u2022 Salit.P roc 1 a ma lion Le Sous-procureur l ATTENDU qu'en ver-général adjoint, ) tu de l'article 101 Jacques Lapointe.1 de la Loi des tribunaux 'judiciaires (Statuts refon- Proclamation ( 'a na< la.Province or PAUL COMTOIS Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace ol God, of the United Kingdom, ('ainula and her other Realms and Territories.Queen, Head of the Commonwealth, defender of the faith.To all to whom these present letters shall come or whom the same may concern, GltKETINO \u2022 Proclamation Jacques Lapointe, / VWHEREAS pursuant Assistant Deputy J wV to section 101 Attorney General.\\ of the Courts of Justice {Act (Revised Statutes, QUEBEC OFFIC/AE GAZETTE, October 16, 1965, Vol.97, So.l> 5.501 .Ins.1904, chapitre 20), le lieiiteaant-gouverneur en conseil peut établir par proclamation pour tout district judiciaire une Cour de Rien-Être Social; Attendu qu'il y u lieu d'établir une Cour de Hicii-Être Social pour les districts judiciaires de St-Hyacinthe, Druimnoml.Arthubaska et Richelieu.A ces causes, du consentement de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un' e the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos: 63 \u2014 $95,000 \u2014 sewers; 94 \u2014 $65,000 \u2014 aqueduct and sewers; 106 \u2014 $164,000 \u2014 sewers, roads, etc; 113 \u2014 $165,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads; 119 \u2014 $105,000 \u2014 drainage: 124 \u2014 $40,000 \u2014 working capital; 125 \u2014 $20,000 \u2014 parks; 130 \u2014 $107,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads; 146 \u2014 $75,000 \u2014 sewers, roads, etc; 107 \u2014 $90,000 \u2014 buying of land; 169 \u2014 $118,000 drainage.For adjudication purposes only, interest shall \\tc calculated as from December 1, 1965.Table of redemption \u2014 S1,044,000 \u2014 20 mm Year Capital November 1, 1966.$ 52,000 November 1, 1967.56,000 November 1, 1968 .59,000 November 1, 1969.17,000 November 1, 1970.18,000 November 1, 1971.21,000 November 1, 1972.- 21,000 November 1, 1973.21,000 November 1, 1974 .23,000 November 1,1975 .24,000 November 1, 1976.27,000 November 1, 1977 .28,000 November 1, 1978 .30,000 November 1, 1979 .32,000 November I, 1980 .33,000 November 1, 1981.29,000 November 1, 1982 .35,000 November 1, 1983 .35,000 November 1, 1984 .37,000 November 1, 1985 .446,000 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, 1966, Vol.97, Mo.JJ 550.1 De plus, .:>oo November 1.1985 .235,500 Moreover, tenders may be forwarded ami shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonde.However, tenders shall he considered for one of the three terms only.Adjudication shall !»«¦ made according t«> law.The successful tenderer agrc«\\s t«> pay for the bonde, principal ami accrued interest, if any, by certified cheque payable al par at Loretteville.Capital and interest an- payable at all the branches in the Province of Queliee of the bank whose name is mentioned in the loan procedure.The mid bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must lie accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued On the bonds to the «late of their be hefc) on Thursday.November 4.1965.at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 220 St-Gérard Boulevard, town of Bélair, county of Quebec, P.Q.The council is not bound to accept the highest or any of the tenders.Bélair.(County of Quebec), October 13.1965.Cl.Al'Di: GllKNIKH, Secretary-Treasurer.Town Hall, 220 St-Gérard Boulevard, Town of Bélair, (Quebec), P.Q.Telephone: 842-7184, code 418.12473 City of Beauport County «>f Quebec Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Georges-E.Boutet, secretary-treasurer.City Hall, 577 Royale Ave., Beauport.county of Quebec, until 8:00 o'clock p.m., Tuesday, November 2, 1965, for the purchase of an issue of $462.500, of bonds for the City of Beauport, county of Quebec, dated November 1, 1965, ami redeemable serially from November 1, 1966 to November 1, 1985 inclusively, with interest at a rate not less than 5%, nor more than 5%%, payable semi-annually on May 1 and November 1, of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos: 393 \u2014$55,000 \u2014 aqueduct ami sewèrs; 399 \u2014- $44,000 \u2014 aqueduct and roads; 405 \u2014 $32,500 \u2014 roads; 413 \u2014 $215,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads, etc.; 414 \u2014 $80,000 \u2022 roads; 418 \u2014 $29,000 \u2014 purchase of machinery; 421 - $7,000 \u2014roads.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from December 1, 1965. 5500 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre 1966, 97' année, No 42 Tuhleau il'unnirtis.sement\t\t$.',62,600 \u2014 gû A nuée\t\tCapital let novembre\t1000\t.8 15,000 1er novembre\t1907\t.16.000 1er novembre\t196g\t.17.000 1er novembre\t1909\t1S.000 1er novembre\t1070\t.18.0(H) 1er novembre\t1971\t.20.000 1er novembre\t1972\t.21.0(H) ter novembre\t1973\t.21.000 1er novembre\t1071\t.22,500 1er novembre\t1975\t.23,600 1er novembre\t1970\t.21.500 1er novembre\t1977\t.23,500 1er novembre\t197S\t.23,500 1er novembre\t1970\t.25,500 1er novembre\t1980\t.26.5(H) 1er novembre\t1981\t.28.000 1er novembre\t1982\t.28,000 1er novembre\t\t 1er novembre\t1984\t.31,500 1er novembre\t1965\t.33,000 De plus, «les soumissions ]>ourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul dee trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Bcauport.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales, dans la province de Québec, de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rSc he tables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant «le l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées «à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 2 novembre 1965, à 8 heures du soir.Hôtel de ville, 577, Avenue Royale, Beauport.comté de Québec.Le conseil se réserve le droit «le n'accepter ni la plus haute ni aucune «les soumissions.Beauport.(Comté de Québec), «'e 13 octobre 1965.Le Secrétaire-trésorier, Gbobobs-B.Boutkt.Hôtel de ville, 577, Avenue Royale, Beauport, (Québec 5), P.Q.Téléphone : 661 -6921, code 418.12474-o Ville de Ste-Philomène Comté de Châteauguay Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Bernard Roussel, secrétaire-trésorier, 14-A, rue Vervais, Ste-Philomène, comté de Châteauguay, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 2 novembre 1965, pour l'achat de $110,000 d'obligations de ia ville- de Ste-Philomène, comté de Tabic of redemption - $.',62,500 ¦ 20 mars Year\tOlapitoi November 1, 1966.\t.$ 15,000 November 1, 1967.\t10,00(1 November 1, 1968.\t.17.00(1 \t November 1, 19*0.\t.18,000 November 1.1971.\t.20,(HH) November 1, 1972.\t21.000 \t November I, 1974.\t.22,500 November 1, 1975.\t.23,500 November 1, 1976.\t.21.5(H) November 1, 1977.\t.23.5(H) November 1, 1978.\t23.5(H) November 1, 1979.\t.25,500 November 1, 1980.\t.26,500 November 1, 1981.\t.28.000 November I.1982\t28,000 November 1, 1983.\t.29.5(H) November l, 1984.\t.31.500 November 1.1985\t.33,000 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered 8J ten-y«'ar short-term ami fifteen-year short-term bonds.However, benders shall be considered for one «>f the three terms only.Adjudication sliall be made according to law.The successful tenderer agrees to puy for the Iannis, principal and accrued interest, if any, by certifie»! cheque payable at par at Mean port.Capital and interest are payable at all branche.in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, us well as at the head office «>f said bank in Toronto.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount >f the present issue and must specify whether interest accrued OU the bonds to the «late of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will Ik?opened and considered at a meeting of the council, to lie held on Tuesday.November 2, 1965, at 8:00 o'clock p.m., in the City Hall.577 Royale Ave., Beauport, county «>f Quebec.The council does not bind itself to accept the highest or any «»f the tenders.Bcauport.(Countv of Quebec), October 13, 1965.(ikoroks-E.Boutkt, Secretary- Treasurer.City Hall, 577 Royale Ave., Beauport, (Quebec 5), P.Q.Telephone: 661-6921, code 418.1247 I Town of Ste-Philomène County of Châteauguay Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Bernard Roussel, secretary-treasurer, 14-A Vervais Street, St«-Philomène, county of Châteauguay, P.Q., until 8:00 o'clock p.m.Tuesday, November 2, 1965, for the purchase of an issue of $110,000 of bonds for the town of Ste-Philomène.county of Châ- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 16, 1965, Vol.97, No.1,2 5507 < hateauguay, datées du 1er novembre 1905 et remboursables par séries du 1er novembre 1900 au 1er novembre 1985 inclusivement, avec inté-r,l à un taux non inférieur il 5% ni supérieur à 0% payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre «le chaque année.Le taux «l'intérêt peut être le même dow toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Réglementa Nos: 83 \u2014 $40,000 \u2014 aoueduc; si \u2014 $49,000 \u2014 égouts; 87 \u2014 812,700 - égouts; 88 \u2014 $8,300 \u2014 aqueduc.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er «lécembre 1905.tableau d'amortissement $110,000 \u2014 20 ans Atmée Capital 1er novembre 1900.$3,000 1er novembre 1967 .3,000 1er novembre 1968.3,500 1er novembre 1909.3,500 1er novembre 1970.4,000 1er novembre 1971.4,000 1er novembre 1972.4,500 1er novembre 1973.4,500 1er novembre 1974.5,500 1er novembre 1975.5,500 1er novembre 1976.5,500 1er novembre 1977.6,000 1er novembre 1978.6,500 1er novembre 1979.0,500 1er novembre 1980 .6,500 ' 1er novembre 1981.7,000 1er novembre 1982.7,000 1er novembre 1983.7,500 1er novembre 1984 .8,000 1er novembre 1985.8,500 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par «hèque visé, payable au pair à Ste-Martine, comté de Châteauguay.Iaî capital et les intérêts sont payables à toutes ie> succursales dans la province de Québec de la hanque dont le nom est mentionné dans la pro-cédure d'emprunt.Lcsdites obligations ne seront pas rachetablcs par anticipation.Chaque soumission «levra être accompagne'* «l'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 2 novembre 1905, à 8 heures du soir, à la Salle de l'École St-René, 14, rue Vervais, Ste-Philo-inène, comté de Châteauguay, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ste-Philomène, (Comté de Chftteaugunv), ce 7 octobre 1905.Le Secrétaire-trésorier, Bbrnaud Roussel.14-A rue Vervais, C.P.130, Ste-Philomène, (Châteauguay), P.Q.Téléphone: 691-1271, code 514.12475-0 teauguay.dated November 1.1905, and redeemable serially from November 1.196») to November 1.1985 inclusively, with interest at a rate not less than 5%, nor more than 6%, payable semiannually on May 1 ami November 1 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos.: s3 810.000 aqueduct; M 5411,000 sewers ; s7 812.700 - sewers ; SS $8.300 aquciluct.Por adjudication purposes only, interest shall be calculated as from December l.1905.Table of redemption tl 10.000 \u2014 20 years Yeur Capital November I, 1906.$3,000 November 1, 1967.3,000 November 1.1968.3,500 November 1.1969.3,500 November 1.1970.4.000 November I, 1971 .4.000 November I, 1972.4.500 November 1.1973.4.500 November 1.1974.5.500 November 1.1975., 5,500 November 1.197»).5.500 November 1.1977.0.000 November 1.1978.6,500 November 1.1979.0,500 November 1.1980.0,500 November 1.1981.7.000 November 1, 1982.7,000 November 1.1983 .7,500 November 1.1984.8,000 November I.1985.8,500 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered SS ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall la* considered for one of tin* three terms only.Adjudication shall l>c made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, it any.by certified cheque payable at par at Ste-Martine.county of Châteauguay.Capital ami interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank whose name is mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to \\% of the amount of the present issue ami must specify whether interest accrued on the bonds t«> the date «>f their delivery is included OT not in the price of the temler.The tenders will Ik* opened and considered at a meeting of the council to be held on Tuesday, November 2, 1965.at 8:00 o'clock p.m., at the St-René School Hall.14 Vervais Street, Ste-Philomène, county of Châteauguay.P.Q.The council is not bound t«) accept the highest or any of the tenders.Ste-Philomène, (County of Châteauguay).October 7.1965.Bkknauu Roi sski.Secretary-T reasurer.14-A Vervais Street.P.O.Box 130.Ste-Philomène, (Châteauguay).P.Q.Telephone: 691-1271.Code 514.12475 5508 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre 1966, 97' année, No Jf Ville «le Terrebonne Comté de Terrebonne Axis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées el endossées « Soumissions pour obligations seront reçues par le soussigné Jean-Jacques l.au/on.sécrétaire-tré-aorier, Hôtel dé vine, 3, rue Bt-Jean-Baptiste, Terrebonne, comté de Terrebonne, jusqu'à h heures p.m., jeudi, le 1 novembre 1005, poui l'achat «le $340,000 d'obligations «le la ville de Terrebonne, comté de Tei rebonne, datées du 1er novembre 1965 et remboursables par séries du 1er novembre 1966 au 1er novembre 1985 inclusivement, avec intérêt à un taux non infélieur à ô( \",, ni supérieur à 6%, payable scmi- annuelleincnt les lei mal et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances, Règlements Nos: 031 815.000 usine «le filtration: 010 $31,300 aqueduc «-t égouts; 017 $2.400 aqueduc: 053 $45.500 \u2014 aqueduc et «'goûts: 002 $175.000 aqueduc et égouts; 071 810,000 usine «l«- filtration; 073 $22,700 aqueduc; 074 $5,400 -aqueduc; 676 $20,000 aqueduc el «'-goût-,; 0n5 812,700 atpicduc et «'-goûts.Pour lins d'adjudication seulement, l'intérêt sera «-aïeule à compter du 1er décembre 1965.Tableau d'amortissantnt\t\tM.',0.000 10 Année\t\t( a pit al 1er novembre\t\t 1er novembre\t1007\t.9,000 1er novembre\ti00s\t.11.000 1er novembre\t1000.\t.11.000 1er novembre\t1070\t.12.000 1er novembre\t1071\t.13.000 1er novembre\t1072\t.13.500 1er novembre\t\t 1er novembre\t1074\t.14,500 1er novembre\t1975\t.15.500 1er novembre\t1976.\t.15,500 1er novembre\t1077\t.16,500 1er novembre\t1978\t.17.000 1er novembre\t1970.\t.18.5(H) 1er novembre\t1980.\t.10.500 1er novembre\t1981\t.21,000 1er novembre\t\t 1er novembre\t\t 1er novembre\t\t 1er novembre\t1985.\t.39,500 De plus, «les soumissions pourront être en-voyées et elles seront prises en considération pour «les obligations à courte échéance «lix ans ou à court»' échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul «les trois termes.L'adjudication sera faite conformément à lu l«>i.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Terrebonne.I*c capital et les intérêts sont payables à toutes l«-s succursales, «lans la province «le Québec, «le la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetehles par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée «l'un chèque accepté à 1% «lu montant de l'emprunt et devra Spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Town of Terrebonne County of Terrebonne Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Jean-Jacques Lau.eon, secretary-treasurer, Town Hall, 3 St-Jean-Baptiste Street, Terrebonne, county of Terrebonne, until 8:00 o'clock p.m., Thursday, November 4, 1905, for the purchusc of an issue of $340,000 of bonds for the town of Terrebonne) county of Terrebonne, dated November 1, 1965, ami redeemable serially from November I, 1966 to November 1, 1985 inclusively, with interest at a rate not less than 5%, nor more than 6%, payable semi-annually on May 1 and November 1 «>f each year.The rate of interest may be the sac for the whole issue or Wt may vary according to maturities.By-laws Nos.031 \u2014 $15,000 \u2014 filtration plant; 646 \u2014 $31,300 \u2014 aqueduct, and sexvers; 647 $2,400 \u2014 aqueduct; 653 \u2014 $45,500 \u2014 aqueduct ami sexvers; 662 \u2014 $175,000 \u2014 aqueduct and sewers; 071 \u2014 $10,000 \u2014 filtration plant; 673 $22,700 \u2014 aqueduct; 074 \u2014 $5,400 \u2014aqued ict; 076 \u2014 $20,000 \u2014 aqueduct and sexvers; 685 $12,700 \u2014 aqueduct and sewers.For adjudication purposes only, interest shall Ik.* calculated as from December 1, 1965.Table of redemption $31,0,000 \u2014 20 yean Year Capital November 1, 1966.$ 9,000 November 1, 1907 .9,000 November 1, 1968.11,000 November 1,1969.11,000 November 1, 1970.12,000 November 1, 1971.13,000 November 1, 1972.13,500 November 1, 1973.14,000 November 1, 1974.14,500 November 1, 1975.15,500 November 1, 1970.15,500 November 1, 1977.16,500 November 1, 1978.17,000 November 1, 1979.18,500 November 1, 1980.19,500 November 1, 1981.21,000 November 1, 1982.21,500 November 1, 1983.23,500 November 1, 1984 .25,000 November 1, 1985 .39,500 Moreover, tenders may lie forxvarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year hosrt-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall l>e ma«le according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Terrebonne.Capital and interest are payable at all brandies in the province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the principal office of the said bank in Toronto.The said bonds will not l>e redeemable by anticipation.Each tender must l>e accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of I he present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender. QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, October JO, 1906, Vol.97, No.42 5509 Les soumissions seront ouvertes et considérées ù nue séance du conseil qui sera tenue jeudi, le i novembre 1005, à s heures du soir.Hôtel de ville, 3.rue St-.lcaii-Bnplistc.Terrebonne.comté de Terrebonne.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Terrebonne, (Comté de Terrebonne), ce 12 octobre 1005.Le Sccrétuirc-trésarier.1 k a \\ -l.\\ < \u2022 Q| i : s Lai zo\\.Hâte! de ville.CI'.00.3, rue St-Jean-Baptiste.Terrebonne.(Terrebonne), P.Q.Téléphone: 666-4123, code 514.l'2470-o Ville de Trois-Riviercs-Oucst Comté de Trois-Rivières Avis public est par les présentes donné que .les soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le sous-igné Roland Desaulicrs, secrétaire-trésorier, 433, rue Lacerte, Trois-Rivières-Ouest, comté de Trois-Rivières, jusqu'à 5 heures p.m., et par après de 8.30 heures p.m., à 9 heures p.m., à la salle de l'Ecole Val Mauricie, Trois-Rivières-Ouest, comté de Trois-Rivières, P.Q., mercredi, le 3 novembre 1905, jxmr l'achat de 8631,000 d'obligations de la ville de Trois-Rivières-Ouest,.comté de Trois-Rivières, datées du 1er novembre 1965 et remboursables par series du 1er novembre 1966 au 1er novembre 1985, inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5%, ni supérieur à 6%, payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le tauv d'intérêt peut être le même pour toute l'émission u il peut varier suivant les échéances.Règlements Nos 137-N-2 \u2014 $115,250 \u2014 pavage, voirie et éclairage de rues; 148-N-l \u2014 $3,900 - voirie; 152-N-l \u2014 $4,600 \u2014 voirie; 1G2-N \u2014 s280,100 \u2014 aqueduct; 163 \u2014 $39,500 \u2014 voirie; 104 \u2014 $151,050 \u2014 voirie; 168 \u2014 $12,900 voirie; 169 \u2014 $23,100 \u2014 voirie.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er décembre 1965.Tableau d'amortissement \u2014 $631,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er novembre 1966.$ 8,000 1er novembre 1967.8,000 1er novembre 1968 .8,000 1er novembre 1969 .8,500 1er novembre 1970.10,000 1er novembre 1971.10,000 1er novembre 1972.10,000 1er novembre 1973.10,500 1er novembre 1974.11,500 1er novembre 1975.12,000 1er novembre 1970.12,500 1er novembre 1977.13,500 1er novembre 1978.14,000 1er novembre 1979.15,500 1er novembre 1980.17,000 1er novembre 1981.16,500 1er novembre 1982.17,500 1er novembre 1983.18,500 1er novembre 1984.19,500 1er novembre 1985 .390,000 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.The tenders will be opened and Considered at a meeting of the council to be held on Thursday, November 4, 1965, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 3 St-Jeaii-Baptistc Street, Terrebonne, county of Terrebonne.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Terrebonne, (County of Terrebonne), October 12, 1005.Jean-Jacques Lauzon, Secretary- Treasurer.Town Hall, P.O.Box 60, 3 St-Jean-Baptiste Street, Terrebonne, (Terrebonne), P.Q.Telephone: 666-4123, code 514.12476 Town of Trois-Rivières-West County of Trois-Rivières Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will la-received by the undersigned Roland Desaul-nicrs, secretary-treasurer, 433 Lacerte St., Trois-Rivières-West, county of Trois-Rivières, until 5:00 o'clock p.m.and afterwards from 8:30 o'clock p.m.to 9:00 p.m.at Yal Mauricie School Hall.Trois-Rivières-West, county of Trois-Rivicres P.Q.on Wednesday.Novemlier 3, 1905, for the purchase of an issue of 8631.0(H) of bonds for the town of Trois-Riviqrcs-West.county of Trois-Rivières, dated November 1, 1965, and redeemable serially from November 1, 1966 to November 1, 1985 inclusively, with interest at a rate not less than 5%.nor more than 6%, payable semi-annually on May l and November l of each year.The rate of interest may l>e the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos: 137-N-2 \u2014 $115,250 \u2014 paving roads and street lighting; 148-N-l \u2014 $3,900 \u2014 roads; 152-N-l \u2014 $4,600 \u2014 roads; 162-N \u2014 $280,100 \u2014 aqueduct; 163 \u2014 $39,500 roads; 164 \u2014 $151,050 \u2014 roads; 108 \u2014 $12,900 \u2014 roads; 109 \u2014 $23,100 \u2014 roads.For adjudication purposes only, interest shall Ik* calculated as from December 1, 1965.Table of redemption \u2014 $631.000 - 20 years Year Capital November 1, 1966.$ 8,000 November 1,1967.8.000 Novem be r 1, 1968.8,000 November 1, 1969 .8,500 November 1, 1970.10,000 November 1,1971.10,000 November 1, 1972.10.000 November 1, 1973.10,500 November 1, 1974.11,500 November 1, 1975.12,000 November 1,1976.12,500 November 1, 1977.13,500 November 1, 1978.14,000 November 1, 1979.15,500 November 1, 1980.17,000 November 1,1981.16,500 November 1, 1982.17,500 November 1, 1983.18,500 November 1, 1984.19,500 November 1.1985 .390.000 Moreover, tenders may be forwarded ami shall la?considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, ten-tiers shall la?considered for one of the three terms only.Adjudication shall la* made according to law. 5510 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 octobre 1965, 97' année, No ipi l/adjudieataire .s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Trois-Rivières.I^e capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province «le Quélwc de la banque dont le nom est mentionné «lans la procedure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal «le ladite haïupic à Toronto.lx'sdites obligation! ne seront pas rechctablcs par anticipation.< \"uaque soumission «levra être accumpagnéc d'un chè«pie accepté égal ù 1% du montant de l'emprunt el devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment «le leur livraison.Lee soumissions seront ouvertes et considé-rées à une séance «lu conseil qui sera tenue mer-«rc«li, le 3 novembre 1965» à B heures du soir, à la Salle «le l'Ecole Val Mauricie, Trois-Rivièrcs-Ouesl, comté de Trois-Rivières, P.Q, Le conseil se réserve le droit «le n'accepter ni la plus haute ni aiu-une «les soumissions.Tmis-Rivières-Ouest, (Comté «le Trois-Rivières), ce 12 octobre 1965./,c SêCrêtû ire-trésorier, Roland Dekaulmrks.433.rue Lacerte, Trois-Rivières-Ouest.(Trois-Rivières), P.Q.Téléphone: 376-7731, code 819.12477-0 Tin- successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Trois-Rivière-.Capital and interest are payable at all bran «lies in the province «>f Quebec, of the bank men tioned In the loan procedure, as well as at the bead office of the sail hank in Toronto.The said bonds will not be re«lecmable by anticipation.Bach tender must lie accompanied by a certified cheque equal to l% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds t«> the «late of their delivery is imdmlcd or not in the price of the teiuler.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to lie held on Wednesday November 3, 1965, at 9:00 o'clock p.m., at the Val Mauricie School Hall.Trois-Rivières-West, county «»f Trois-Rivières.P.Q.The council oulevard Levesque, sur une profondeur de neuf cent quarante pieds (940') mesurés au long de la ligne de son côté sud-ouest, de là en se rétrécissant à la largeur de trois cent soixante-deux pieds et trois dixièmes d'un pied (302.3') pour la profondeur restante dudit lot trots cent soixante, et ledit morceau de terrain lx>rné en front au sud-est pur le boulevard Lévesquc.en arrière SU nord-ouest par lu ligne separative entre la paroisse «le St-Vincent de Paul et la paroisse de St-François de Sales, d'un côté au nord-est par le lot trois cent soixante et.un dudit cadastre et de l'autre côté au sud-ouest par le résidu dudit lot trois cent soixante.Sheriffs' Sales PUBLIC NOTICE, is herebv given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be mid at the respective times and places mentioned below.BEDFORD Canada \u2014 Province of Quebec District of Bedford Superior Court, (BARTHELEMY LOI-No.14,349.< -D SELLE, bricklayer of ' Dunham, district of Bedford, plaintiff, ps ROGER FAUCHER INC., body politic and corporate having its head office in Cowansville, district of Bedford, defendant.As lielonging to the defendant: \"An emplacement situated in Domaine d'Estrie, in South-Stukely-Sud, county of Shefford, known and designated as No.229 of the official subdivision of lot one hundred and twenty-eight (128-229) in the official cadaster of the township of Stukely, measuring one hundred ami seventeen and seven-tenths feet (117.7') on its east line which lies along a street being No.128-221, one hundred feet (100') on its north line and seventy-nine and one-tenth feet (79.1') on its west line, having an area of nine thousand six hundred and twenty square feet (9620 sq.ft.), the whole English measure, more or less.With the buildings thereon erected.\" To be sold at the parochial church door of St-Édouard d'Eastman.district of Bedford, WEDNESDAY, the THIRD day of NOVEMBER, 1965, at TWO o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Paul St.Martin, Court House, Sheriff.Sweetsburg.P.Q., September 10, 1905.12204-39-2 M 0NTREAL Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: ( BEAVER HALL INVEST-No.646 485.{ MEATS LTD.plain-l tiff, m JULIUS KUGLER, defendant.That certain emplacement situate in the parish of St-Vincenl de Paul, county of Laval, known and designated as being paît of lot number three hundred and sixty (Pt.300) on the official plan ami book of reference of the parish of St-Yineent de Paul, measuring the said part four hundred and live feet (405') in width in front along Blvd.Levesque by a depth of nine hundred and forty feet (940') measured along its southwest side line, thence nan-owing to a width of three hundred and sixty-two feet and three-tenths of a foot (362.3'> for the remaining depth of the said lot three hundred and sixty, and hounded the said part in front t«> the southeast, by Levesque Boulevard, in rear bO the northwest by the division line between the parish of St-Vincent de Paul and the parish of St-François de Sales, on one side to the northeast by lot three hundred and sixty-one of the said cadastre and on the other sale to the southwest by the residue of said lot three hundred and sixty. 5512 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, U octobre IMS, 97' année, No W À déenrle.Une partie «lu lot originaire numéro trois «eut quarante-neuf (Ptic 349) aux plan et livra de renvoi officiels «le la paroisse de St Vincent «le Paul, mesurant cent quarante pieds (110') «le largeur sur six cents pieds (000') de profondeur, «\u2022ontenant une superficie de f original lot number two hundred and twenty-three (223-33) on the official plan and book of reference of the town of Lachine, measuring ninety-eight feet and five-tenths of a foot in width by one hundred and thirty feet in depth.English measure and more or less, with the apartment building in course of construction thereon hearing civic number 2650 Louis Paré Street.B) Redivision lot number thirty-four of original lot number two hundred and twenty-three (223-34), on the said official plan and booh of reference measuring one hundred and twenty-nine feet and five-tenths of a foot in width in rear in its northerly line by a depth of two hundred and thirty-five feet in its westerly line.English measure and more or less, with the apartment building in course of construction QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 10, 1905, Vol.97, So.& 55 J 3 le numéro civique 2090, rue Louis Paré, dont le i ni i r ouest est mitoyen.» l'our être vendus ù mou bureau, en la ville de M.u.tréal, le VINGT-NEUVIEME jour d'OCTOBRE 1905, à DIX heures de lavant-midi.U Shérif, Bureau du Shérif, Bkunakd Sahiuzin, ch.Montréal, 20 septembre 1006.12200-39-2 Fieri Facias de It unis et de Terris ( 'our Supérieure District de Montréal Montréal, à savoir: i TYAME ALFREDA LE- Xo 016 205.< U VESQUE, épouse judi-' claire ment séparée de r|>s et de biens de Eloi Dubé, demanderesse, vs GEORGES LAUREN DEAU, défendeur.< Un terrain situé dans la grande Ile, municipalité de la paroisse St-Joscph de Chainhly, dans le comté de Chambly, connu et désigné sous les numéros mille soixante-dix et mille soixante et onze de la subdivision officielle du lot originaire numéro trois cent cinquante-trois (353-1070-1071) c sold at the church door in Beauport, on the NINETEENTH day of NOVEMBER next, at TEN o'clock in the forenoon.Alukkt F.Racbttk, Sheriff's Oflice, Deputy-Sheriff.Quebec, October 8, 1005.12472-42-2 (First insertion: October 10, 1986] [Second insertion: November6, 1965] ARRÊTÉS eu Conseil INDEX No I 2 ORDERS in Council 1996-A 1996-A 1996-B 1996-B Imprimerie, Montréal Printing, Montreal Débardeurs.Sorel Longshoremen.Sorel 5479 5479 5481 5481 AVIS NOTICES Allaire, Pernand (Requête Petition) .5453 Askonajser, Maser (Requite Petition).5451 Corporation «>f the Chairman and Trustees «>f the Common of Laprairie (Diet, assets.) 5454 Corporation des Président el Syndics de la Commune «!«\u2022 Laprairie (Diet, actif) .5454 Patterson.Irene (Requite Petition).5453 St-Joscph de Chambly.par.(Requête Petition).5453 Smos/ewcr.Walter Julius (Rsquite Petition).5453 CAISSES SAVINGS d'épargne et de «-redit «i/i«7 credit savin its Caisse Populaire Saint-Ferdinand «le Laval (La) (Form.).5454 P.S.& P.Local 142 Credit amion (Ext.terr.).5455 COMPAGNIES Avis relatifs à la loi des COMPANIES Notice relative to the Act of Autorisée Licensed ù faire des affaires to do Business Band-Ore Gold Mines Limited.545.\") Chartes\u2014- Charters \u2014 Abandon de Su render of Bronstcin Bros.Ltd.5456 Exclusive Furniture Imports Ltd.5456 Fortclaire Realty Ltd.5155 Lavoie & Bouchard limitée.5-155 Div< Miscellaneous Association des maîtres-imprimeurs de Montréal, incorporée (I/) (Dir.- Régi.By-law.\").5456 Centre Notrc-Duinc «le l'Enfant (Sherbrooke) inc.(RègL- By-laws).5456 Cie immobilière Viger ltée (Dir.).5457 Entreprises C D E née (Les) (Dir.).5457 Fonds de Construction «le Saint-Benott- «lu-Lac inc.(Le) (Rêgl.- By-laws).5457 Historical Diorama Ltd.(Dir.).5457 Mailman Corporation Limited (Dir.).5457 Marvel Products Limited (Dir.).5457 Roy (J.-Léon) & fils, limitée .5457 Sons et lumières historiques inc.(Dir.).5457 Torah Schools for Israel (Règl.- By-laws) 5457 I.c tires patentes Letters Patent Agences Futura inc.(Les).Ascension Forest Products Lt«l.(L').Association des employeurs «le l'industrie de l'automobile inc.(L').Association «les parents des étmliants de Châteauguay inc.(L').Atlan Industries, Limited.Automotive Claims Appraisal (Jo.Automotive Industry Employers' Association Inc.Baie-Comeau Tire Center Inc.Barillet (Jonquière) ltée (Le).Beaulieu & Menard Construction Ltd.Beignes du Chef inc.(Les).Belair Auto Body & Painting Inc.Belfo inc.Bilodeau (Benoît) inc.Blackhawk Paper Waste and Salvage Corp.Boxer (Dave) Enterprises Inc.Centre d'art de Percé inc.(Le).Centre des études universitaires de Trois-Rivières, inc.(Le).Centre de vitres de Montréal inc.Centre de pneu Baie-Comeau inc.< 'lia m plain Brokerage Inc.Charme & beauté Lise Watier inc.Château Investments Ltd.Chauffage Royal (Dolbeau-Mistassini) ltée.Chicoutimi transmission automatique 5412 5442 6412 54l:l 5413 5414 5412 541s 5411 5421 542: 5411 541\"' 5415 inc.Cie immobilière Lagueux-Thél>erge inc.Ci ne-Cam Corporation.Ciri inc.City Auto Parts Inc.Club d'Archer Élan de Chicoutimi inc.Community Transports Ltd.5415 5410 5410 5410 541s 5418 5423 541 s 541'.' 541\" 541'' 5420 5420 5420 5421 5421 5450 QUEBEC OFF Id I.IL GAZETTE, October 10, 1006, Vol.ill.No.12 5515 Lettres patentes letters l'aient (mite) (continued) < ompugnie de plomberie Palmers (Quelle) limitée (La).5139 Construction lleaulieu & Ménard ltée.5421 Corporation de développement et prêts de Montréal ltée____-.5422 Côte des Neiges Radiological Centre Inc.5422 Courtage Champlain inc.5423 Delormier Auto Acceptance Ltd.5423 Donut Chef Inc.(The).5423 Doran entreprises inc.5424 Druckman (Ralph) Inc.5424 D.S.Coatings Inc.5444 Dumais (Maurice) inc.5424 Dynamic Welding Co.Ltd.5425 Dynatrust Ltd.5425 École Commerciale ( oté inc.(I/).5425 Editions D.U.F.inc.(Les).5426 Éditions Fain inc.(Les).542b Élégants importations inc.(Aux).5420 Kntreprises Lopack ltée.5427 Fatima Furniture Ltd.5437 Ferratte inc.5427 Fiala The Jeweller Inc.5427 G & A Service Station Ltd.5428 Gagnon (Lionel) et fils inc.5428 Garage Morin & Desmeules inc.'5429 (ilass Centre of Montreal Inc.5418 Grande Côte Gardens Inc.5429 Hébert et Langlois ltée.5429 Hôpital St-Vincent de Paul de Sherbrooke .5430 Hymns Industrial Complex Inc.5430 Ida-Lynne Inc.5430 Immeubles Côté inc.(Les).5431 Immeubles Miko inc.(Les).5431 Imprimerie Normandie ltée.5431 J & K Air Conditioning Ltd.5432 Jardins Grande Côte inc.5429 Joaillier Fiala inc.(Le).5427 Joints International ltée (Les).5432 Kenmac Investments Ltd.5432 Lauzon Lumber Inc.5433 Laval Autorama ltée.5433 Lektronic Sales Ltd.5433 levesque (W.W.) inc.5434 Librairie M.C.inc.5434 Lin Huron Inc.5435 Lithographie Mt-Royal Offset Inc.5435 Loisirs de Ste-Clotilde (Les).5435 I .opack enterprises Ltd.5427 Lucerjam Inc.5430 M.C.Stationery lue.5434 Marché R.Mayrand ltée.5430 Marché St-Basile inc.5430 Meubles Fatima ltée.5437 Montreal Polyclinic lue.5442 Motel 07 Ltd.5437 Multitcx Limited.,.5437 Optique Laval, liée (L').5438 Oxford 07 inc.5438 Oris lue.5438 P.P.Electric Inc.5439 Palmers Plumbing Supply (Quebec) Limited.5439 Papillon (Rolland).5410 Pelletier (P.A.) ltée.5440 Pétrole Quevillon limitée.5440 Placements des Huit inc.5441 Place Stc-Thérèsc inc.5441 Poirier (.Michel) automobile ltée.5441 Polyclinique de Montréal inc.5442 Produits forestiers L'Ascension ltée (Les) .5442 Ramoneurs du Sud inc.(Les) .5442 Quebec Lead Refiners [ne.5443 Quevillon Petroleum Limited .5440 Rapid Data (Quebec ) Inc.04 13 Regis Antiquaire inc.5443 Revêtements D.S.inc.5444 Rockland Quarries Inc.54 11 Salon île coiffure Tropical inc.5445 Salon Vogue Ltd.5445 Sandi's Inc.5445 Sani Industries Ltd.5446 Savons Black Lake limitée ( Les) .5446 Seguin (Maurice) inc.5446 Service de lessiveuse Ste-Foy inc.5447 Sharinor Inc.5117 Sian Knitwear Boutique (Fairview) Ltd.5447 Sun Luck Restaurant Ltd.5448 Sunnydalc Cleaners lue.5448 Top Investment Ltd.5448 Torah Schools for Israel.5449 Tourigny (F.) construction limitée.5440 Transport d'écoliers Chic, inc.5450 Transports communautaires ltée (Les) 5150 Tiimeii Corporation.5450 Veilleux construction inc.5451 Versailles Hair Products [ne.5451 Wellington Supermarket Inc.5451 West End Auto Inc.5452 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Webster Realties Co.Inc.5152 Sièges SOCUMUf Head Offices Acier Wimco Limitée (L*) .5402 Aqua Traitement Ltée .5463 Asselin (Ray) Inc.5458 Association «les domaines joyeux de St- Alexandre (L').5458 Better Cleaning & Laundry Equipment Inc .545K Better Equipment Inc.5402 Blue Bonnets Realties Inc.5450 Canada Drug Limited.5463 Canada Drug Limitée.5403 Capri Apartments Limited.5459 Colman (Philip! Corporation.5459 Concordia Estates Limited.5459 Constructions Dionne & Duval Inc.(Us).5402 Dean's Cycle & Sports lue.5402 Domaines Concordia Limitée.5459 Eddy's Enterprises Inc.5462 Enterprises C.D.E.Ltée (Les).5459 Enterprises Eddy Inc.(Les).5402 Franchise Equipment Service Inc.5403 Garage Lucien Inc.5464 [ssenman (Arnold) Corporation.5460 Kensington Investment Corp.5100 Marché St-Louis (Trois-Rivières) Ltée.5463 MaroOUX Construction lue.5463 Marisss Industrial Sites Corp.5460 Metropolitan Industrial Park Inc.5400 Micheline Cleaners Inc.5458 Nerenberg (Norman) Corporation 5460 Perry (Kenneth) Corporation .5461 Place Bonaventure Inc.5401 Provincial Aviation Inc .5458 Redfern Corp.5461 Reservation Investment Corp.5101 5510 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEIIEC 10 octobre Ma, 97' année, No U Sii'»cs Mii'i;iu\\ Head Offices {suite) (continued) Salaison Lafontaine Packing lut'.5464 Service Régional «les Bibliothèques de West-Island.5464 West-Island Regional Library Service.5464 Westmount Renovation Ltd 5461 Wimco Steel Limited 5462 Zulapa Mining Corporation Limited \"> l\">s Curatelle publique Public Curatorslùp Successions racuntes: Vacant Estates: Rousseau.Raymond 5464 DEMANDE tPPLICATION a lu Legislature to Legislature Scheflcrville.ville town 5404 EXAMEN EXAMINA TION des Agronomes iuronomists Étude Studv 5465 MINISTÈRES HEP A R T MENT AL affaires inunieipules Municipal Affairs Pointe-LebeL village (Publ.).6467 MINISTÈRES DEPARTMENTAL Éducation Education Municipalité scolaire de: School Municipality of: Côte-St-Luc (Dam.Appt.).5407 St.Armand West Prot.(Dem.-Appl.) 5467 Terres et Forêts Lands and Forests Cadastre: ( adastre: Laval, canton - township.5468 Lussier, canton - township.5467 Ste-Thérèse de Blainville, par.5468 Travail Labour Industrie ou métiers de: I ndustry or T rades of: Commerce, détail, Chicoutimi (Mod.) 5407 Employés de garages, Granby (Mod.).5497 Garage employees, Arlliabaska (Amend.).5499 Garage employees, Granby (Amend.) 5497 Garage employees, Sherbrooke (Amend.) 5498 Retail trade, Chicoutimi (Amend.).5497 Salariée de garages, Artliabaska (Mod.) 5499 Salariée de garages, Sherbrooke (Mod.) 5498 NOMINATIONS APPOINTMENTS Conseils en loi de la Reine.5501) Divers.6500 Miscellaneous.5500 Queen's Counsel.6500 PROCLAMATION PROCLAM ATIit \\ Establishment of a Social Welfare Court for the districts of St-Hyacinthe, Drummond, Arthabaska and Richelieu._.5500 Établissement d'une Cour de Bien-Être Social pour les districts de St-Hyacinthe, Drummond, Arthabaska et Richelieu .5500 SOUMISSIONS TENDER s Beauport, cité - city.55118 Bélair, ville - town.5501 Dollard-des-Ormeaux, ville - town.551 12 Franquelin, c.s.-s.c.(Correction).5501 Papineauville, village.550.1 St-Léonard, cité - city (Correction).5502 Ste-Philomène, ville - town.550»i Terrebonne, ville - town.550s Trois-Rivières-Ouest-West, ville - town 5509 SYNDICAT S YNDICA TES Professionnel Professionol Syndicat interprofessionnel de la fonction publique du Québec (Const.-Inc.).55 lu VENTES SALES Effets non-réclames Unclaimed Baggage Canadian Pacific Express Company.5510 SHÉRIFS SHERIF! - Bedford Bedford Loiselle Al Roger Faucher Inc.55 M Montréal Montreal Beaver Hall Investments Ltd.Si Kugler 551 I Canada Life Assurance Company vs Blumart Enterprises Inc.5512 Levesque m Laurendeau.5513 Québec Quebec Bernier vs Boucher.5513 Rosco Metal & Rotting Products Ltd.vs Doyon.5513 Taxes Taxes Hull, cité city.5468 Shawinigan-Sud, ville - town.5478 I*e Ministère des Postes, a Ottawa, a autorisé l'affranchissement en numéraire et l'envoi comme objet de deuxième classe de la présente publication.Authorised as second class mail by the Post Office Department, Ottawa, and for payment of postage in cash.-A "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.