Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 23 avril 1966, samedi 23 (no 16)
[" 98* année vol.«« 28 \u2022 N° 16 2285 flux H le iillilieIh1 à Québec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE Québec, samedi 23 avril 1966 Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la reine, HA tel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais ties intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût «les annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.0° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre «lu Ministre des Finances.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur OU pour des raisons d'ordre administratif.8e Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Imprimeur de la reine avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Quebec.Saturday, April 23.1966 Rules 1.Address all communiciations to: The Queen's Printer, Parliament Buildings, Quebec.2.Supply advertising copy in the two official languages.When copy is supplied in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Pay cash and l>efore publication for advertising copy according to the rates set forth below, exception when the copy is to be published several times.It that event, the interested party shall pay upon receipt of his account and before the second insertion: otherwise this insertion will he suspended without further notice and without prejudice to the Queen's Printer who will refund any overpayment.5.Subscriptions, price of documents, etc., are payable strictly in advance.6.Remittance must be made to the order of the Department of Finance, by cheque or money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the dead line for receiving notices, documents or advertising copy expires at noon on Wednesday, unless it is a holiday.In that event the dead line is noon, on Tuesday.Notices, documents or advertising copy not received on time will be published in a subsequent edition.Moreover, the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, because of their length or for reasons of administration.8.Any demand for cancellation or any remittance of money is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties arc requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Publiée par le Gouvernement de la Province / Published by the Provincial Government L'Imprimeur de la reine, roch lefebvre, Queen't Printer \u2014 Québec 2280 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 23 avril lOliO, OS' année, n° Hi Tarif des annonces, abonnements, etc.Premiere insertion: 30 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 10 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: Si «les 100 mots.Exemplaire séparé: 40 cents chacun.Feuilles volantes: $1.50 la douzaine.Abonnement: $10 par année.N.B.\u2014 Lee chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Oazctte pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni «le notre traduction.Les avis publiés une seid fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.VImprimeur de la reine, Rom Lefebvrk Hôtel du Gouvernement, Québec, 5 mai 1902 13377 \u2014l-52-o Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 30 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $1 per 100 words.Single copies: 40 cents each.Slips: $1.50 per dozen.Subscriptions: $10 per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document numhci ; the second to that of the edition of the Oagette for the first insertion; the third to the number of insertion, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our trans, lation.Notices published but once are followed only by our document number.Koch Lbfbbvre, Queen'.-,- Printer Parliament Buildings, Quebec, May 5.1062 13377 \u2014l-52-o Lettres patentes A.!.équipement inc.A.L.Equipment Inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes, en date «lu 21e jour «le février 1966, constituant en corporation: Adrienne Lebouthil-lier, ménagère, épouse séparée de biens de Julien Losier, 29, Irving Place, Dollard-des-Ormeaux, Louise Bourque, ménagère, épouse séparée «le biens «le Marcel Privé.1180, Croissant Danville.Laval, et Gilles Godin, avocat, S00.boulevard Houde.St-Lambert.pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de construction et faire le commerce «le toutes sortes d'équipements, machineries et véhicules.bous le nom de « A.L.équipement inc.\u2014 A.L.Equipment Inc.», avec un capital total «le $40,000.divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 390 actions privilégiées «le $100 chacune.I-iC siège social de la compagnie est à Pointeaux-Trembles, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-sccrftaire de la province, Raymond Dorviu.k.14725-0 011-00 Agence de voyage Intercontinental inc.Intercontinental Travel Bureau Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Ixn des compagnies, l'administrateur du gouvernement «le la province a accordé des lettres patentes, en date «lu 9e jour «le mars 1900, constituant en corporation: Marcel Allard, vendeur, 800, Duhith est, Montréal.Claude Boi-leau.vendeur, 1230, Bcauhicn est.app.9, Montréal, et Roger Leroux, vendeur, 10025, Francis.app.25.Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme agence de voyages et «le transport, sous le nom de « Agence «le voyage Intercontinental inc.\u2014 Intercontinental Travel Letters Patent A.L.équipement inc.A.L.Equipment Inc.Notice is given that Under Part I ol tin-Companies Act.letters patent, bearing «late the 24th day of February.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Adrienne Lebouthillier, housewife, wife separate as to property of Julien Losier, Irving Place, l)«>llar«l-des-()rmeaux.Louise Bourque, housewife, wife separate as to property «>! Marcel Privé.UNO Croissant Danville, Laval, and (iilles Godin, lawyer, 800 Houde Boulevard, St-Lambert, for the following purposes: To carry on business as a construction company and to deal in all kinds of equipment, machinery and Véhicules, under the name «>l \"A.L.équipement inc.-\u2014 A.L.Equipment Inc.\".with a total capital stock of 140,000, divided into 1.000 common shares of $1 each ami into 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Poind aux-Trembles, judicial district of Montreal.Raymond Douvillb, Assistant Secretary of the Province.14725 611-66 Agence de voyage Intercontinental inc.Intercontinental Travel Bureau Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 9th day «>f March.1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Marcel Allan!, salesman.800 Duluth Bast, Montreal, Claude Boileau, salesman.1230 Bcauhicn East.Apt.9.Montreal, and Roger Leroux, salesman.10(525 F ranci-.Apt.25, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a travel ami transport agency, under the name of \"Agence «le Voyage Intercontinental inc.\u2014 Intercontinental Travel QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 88, I960, Vol.9S, No.10 2287 Bureau Inc., avec un capital total de 140,000, divisé 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 2182, Mont- lioyal est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dorviu.k.11725-c lOOO-oo Bureau Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at 2182 Mount Royal East, Montreal, judicial district of Montreal.Raymon d 1 >0U viu.k, Assistant Sccretarn of the Province.14725 1000-00 Amiga inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de mars 1966, constituant en corporation: Kmé Lacroix, 280, nu- Appin.Mont-Royal.Claude Thivierge.105, Thackeray, Bcacousficld.tous deux avocat.-., cl Jacqueline Matte, secrétaire, fille majeure, S390, Drolet, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille holding), sous le nom de « Amiga inc.», avec un capital total de $120,000, divisé en 50 actions onIinaires de $100 chacune et en 1.150 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siî'ge social «le la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Mont irai.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond DouviLLK.14725-0 011-00 Amiga inc.Notice is given that under l'art I of the Companies Act, letters patent, l>earing date the 7th day of March, 1900, have been issued by the Administrator «>f the Government of the Province, incorporating: Kmé Lacroix, 280 Appin Street, Mont-Royal, Claude Thivierge, 105 Thackeray, lleaconsfiehl, both lawyers, and Jactpieline Matte, secretary, fille majeure, 8390 Drolet.Montreal, for the following pur|k>ses: To carry on business as a holding company, Under the name of \"Amiga inc.\", with a total capital stock of $120,000, divided into 50 common shares of $100 each ami into 1,150 preferre«l shares of $100 each.The hea«l office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dolvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 911-00 Arsenaiilt Aircraft Services Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Ix>i des compagnies, l'administrateur «lu gouvernement «le la province a accordé des lettres patentes, en «late «lu Se jour «le mars 1906, constituant en corporation: Robert Gi-rouard, notaire.Monicpic Lefebvre, ménagère, épouse séparée «le biens «iudit Robert Girouard, tous «leux «le 70.1er avenue.Terrasse-Vaudreuil.el Monique Bouiselle, secrétaire, fille majeure.335, 2e avenue.Ilc-Pcrrot.pour les objets suivants: Entretenir, réparer et vendre «les hélicoptères, avions et accessoires et thmuer Unit service nécessaire, sous le nom «le « Arsenaiilt Aircraft Services Inc.'\", avec un capital total «le $40.000.divisé en 4.000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège stx-ial «le la compagnie est 263, Cherrystone Drive.Pincourt, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Dorviu.k.14725-0 471-00 Arsenaiilt Aircraft Services Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, l>earing «late the 8th «lay of March, 1900, have been issue«l by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: R«>bert (iirouard, notary, Monique Lefebvre, housewife, wife separate as to property of the sai«l Rolnrt (Jirouar«l, both of 70, 1st Ave.Terrasse-Vaiulreuil.and Monique Rousscllc, secretary, fille majeure.335, 2n«l Ave.Ile-Perrot.for the following purposes: To maintain, repair ami sell helicopters, airplanes and accessories, and to give all necessary services, under the name of \"Arsenaiilt Aircraft Services Inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 4.000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 2G3 Cherrystone Drive, Pincourt.judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 471-00 association des commerçants et hoteliers de Ste-Anne-de-Beaupré Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie «le la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour «le mars 1966, constituant en corporation sans capitalisions: Guy Blouin, commerçant.Benoît Paré, commerçant, et Albert J.Bilodeau, hôtelier, trois «h» Ste-Anne-de-Beaupré, pour les objets suivants: Grouper en association les commerçants, hôteliers et moteliers «le Ste-Anne-de-Beaupré et des municipalités environnantes, sous le nom «le « Association des commerçants et hôteliers de Ste-Anne-de-Beaupré ».Association des commerçants et hôteliers de Ste-Anne-de-Beaupré Notice is given that under Part III of the Companies Act.letters patent, l>caring date the 4th day of March, 1906, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Guy Blouin, trader, Benoît Paré, trader, and Albert j.Bilodeau, hotel keeper, all three of Ste-Anne-«le-Beaupré, for the following purposes: To group in association, the traders, hotel keepers, motel keepers of Ste-Anne-de-Beaupré and the surrounding municipalities, under the name of \"Association «les commerçants et hôteliers «le Ste-Anne-de-Beaupré\". 2288 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril 190(1, 98' année, n° 10 Le moulant suquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de S10,000.Ijc siège social de la corporation est à Ste-Anne-de-Beaupré.district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Dorviu.k.14725-0 038-06 L'Association des employés indépendants de Ciment Indépendant inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la I,oi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a acconlé des lettres patentes, en date du 1 le jour de mars 1066, constituant en corporation sans capital-actions: Paul Pclland.opérateur, St-Kélix-de-Valois.Pierre Labrosse, technicien.762, Ladou-ceur.loliette, Cléophas Yalade, journalier, rang du Vieux Moulin.Juliette.Roger Morel, électricien, 590.Montcalm.RejKMitigny.et Bernard Lebeau, électricien.10, Parc Dumoulin, Rcpcn-tigny.pour les objets suivants: Etudier, promouvoir, protéger et développer de toutes manières les intérêts économiques, sociaux et éducationnels des membres de la corporation, sous le nom de « L'Association des employés indépendants «le Ciment Indépendant inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de §20.000.Le siège social île la corporation est à .loliette, district judiciaire «le .loliette.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond DouviLLB.14725-0 1029-66 Auto-Lave du boulevard inc.Boulevard Car-Wash Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Ix>i des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 3e jour de mars 1900.constituant en corporation: Roland Four-nel, commerçant, Ste-Martine, comté «le Châ-teauguay, Gérard Mat hou, comptable, 299, rue De Lorraine.Ixmgueuil.et Ixmis-Guy Denis, soudeur, 5451, 7e avenue, Montréal, pour les objets suivants: Installer «les machines automatiques aux fins «le laver les voitures automobiles, sous le nom de «Auto-Lave du boulevard inc.\u2014 Boulevard Car-Wash Inc.», avec un capital total «le $40.000.divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur nominale «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montrai, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dotrville.14725-o 293-00 Autos-Repos, inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement «le la province a acconlé des lettres patentes, en «late «lu 9e jour île mars 1906, constituant en corporation: Luc Geoffroy, avocat, 821, boulcvanl Briand, Chambly, Guy Bissonnette, avocat, 4351, Oxford, Montréal, et Jeannette Brodeur, secrétaire, fille majeure, 3450, Durocher, app.31, Montréal, pour les objets suivants : To amount to which the value of the animal revenue from the immoveable property which the corporation mnv own «»r acquire IS to he limited is $10.000.The head office of the corporation is at Ste-Anne-de-Beaupré, judicial district «>f Quebec, Raymond Dorviu.k, Assistant Secretary of the Province.14725 928-60 L'Association des employés indépendant* de Ciment Indépendant inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act.letters patent, bearing date the 11 th day of March, 1066, have been issued by the Government Administrator «»f the Province to incorporate a corporation without share capital: Paul IVIIaml.operator, St-Félix-dc-Valois, Pierre Labrosse.technician.702 Ladou-CCUr, Joliette.Cléophas Yaladc.laboureur.Vieux Moulin range.Joliette.Roger Morel, electri-cian.599 Montcalm, Repentigny, and Bernard Lebeau.electrician, 10 Pare DunuMiliii.Repen-tigny.for the following purposes: To study, promote, protect and develop in any way possible, the ecomunic.social and educational interests «>f the corporation's members, under the name «>f \"L Association «les employés indépendants «le Ciment Indépendant inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire ami hold is to be limited, is $20.000.The head office of the corporation is at Joliette.judicial district of Joliette.Raymond Doevu.u:.Assistant Secretary of the Province.14725 1029-66 Auto-Lave du boulevard inc.Boulevard Car-Wash Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 3rd day of March.1900.have been issued by the Administrator «>f the Government of thf Province, incorporating: Rolaml Fournel, trader.Ste-Martine.county of Châteauguay, Gérard Mathon, accountant.299 De Lorraine Street.Longueuil, ami Louis-Cuy Denis, welder.5451, 7th Avenue.Montreal, for the following purposes: To install automatic machines in onler t«> wash motor véhicules, under the name of \"Auto-Lave «lu boulevard inc.\u2014 Boulevard Car-Wash Inc.\".with a total capital stock of $40.000, divided into 400 common shares of a nominal value of $100 each.The head office «>f the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raym«).nd Dorvn.u:.Assistant Secretary of the Province.14725 298-68 Autos-Repos, inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent.Iicaring date the 9th (lay of March, I960, have been issued by the Administrator «>f the Government of the Province, incorporating: Luc Geoffroy, advocate, B21 Briand Blvd., Chambly, Guy Bissonnette.advocate, 4351 Oxfonl, Montreal, ami Jeannette Brodeur, secretary, fille majeure, 3450 Durocher, Apt.31.Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, April 23, 19m, Vol.9S, So.10 2289 Pain I*' commerce i des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé des lettres patentes, en «late du 17e jour «le février 1900, constituant en corporation: Saul Hamlelman, avocat, 175, chemin Dufferin, Hampstea«l, Lilian Iteinhlatt, avocate, épouse séparée de bieni de Moc Reinhlatt, 4520, Itosedale, Montréal, Anne Brown secrétaire, fille majeure, 7030, chemin ( Y>te-St-Luc, Montréal, et Stanley Cy-Irynhaum, avocat, 234, Sheraton Drive, Montreal Ouest, ]m)iir les objets suivants: Exercer un commerce de restaurateurs, sous le nom «le « I/C Bergerac inc.», avec un capital total «le $40,000, «livisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et 390 actions privilégiées de $100 chacuen.Ia' siège social de la compagnie est à Montrai Nord, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.14725 822-00 To carry on business dealing in automobiles, and to act as garagemen, un«ler the name of \"Autos-Re|k)s, inc.\", with a total capital stock of $00,000, divided into 100 common shares of $100 each ami 500 preferred shares «>f $100 each.The bead office of the company is at 2045 Ya-l«)is, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 952-66 Le Bergerac inc.Notice is given that umler Part I of the Companies Act, letters patent, l>earing date the 17th day of February, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, iiicorpnratiii.tr: Saul Handelman, advocate, 175 Dufferin Road, Hampstead, Lilian Reinblatt, advocate, wife separate as to property of Moe Reinblatt, 4520 Rosedale, Montreal, Anne Hrown, secretary, fille majeure, 7030 Côte-St-Luc Road, Montreal, ami Stanley Cytrynbaum.a«lvocate, 234 Sheraton Drive, Montreal West, for the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, under the name of \"Le Bergerac inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $10 each and 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal North, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-o 822-66 Gilles Bouchard Itce Avis est tlonné qu'en vertu «le la première partie «le la Ix>i «les compagnies, l'atlministra-teur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date «lu 7e jour de mars 1966, constituant en corporation: Gilles Bou-chard, 8644, du Buisson, Montréal, Irénée Bouchard, 8595, Tellier.Montréal, Paul Bouchard, 8, Ixjulevard Lévesque, Repentigny, André Bouchard, 45, de Bretagne, Repentigny, ( 'laude Bouchard, 8656, du Buisson, Montréal, et Bernard Bouchard, 246, boulevard tl'Iberville, Repentigny, tous six marcliands, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «le transport et faire le commerce du bois, de l'huile, du char-bon et de la glace, sous le nom «le « Gilles Bouchard ltée », avec un capital total de $10,000, «livisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale «le $10 chacune.I^e siège social de la compagnie est 2085, rue Oahlwin, Montréal, district judiciaire de Mont-réal.Le Sowi-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.14725-d 963-66 Ludger Bouchard inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 10e jour de mars \u2022 066, constituant en corporation: Ludger Bouchard, meunier, Thérèse Robert, ménagère, épousa séparée de biens dudit Ludger Bouchard, et Aimé Bouchard, rentier, tous trois de St-Gédéon, comté de Frontenac, pour les objets suivants: Gilles Bouchard ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, tearing date the 7th day of March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Gilles Bouchard, 8644 «lu Buisson, Montreal, Irénée Bouchard, 8595 Tellier, Montreal, Paul Bouchard, 8 Lévesque Boulevard, Repentigny, André Bouchard, 45 de Bretagne, Repentigny, Claude Bouchard, 8656 du Buisson, Montreal, and Bernard Bouchard, 246 Iberville Bouchard, Repentigny, all six trailers, for the following purposes: To carry on business as a transport company and to deal in wood, oil, coal and ice, under the name of \"Gilles Bouchard ltée\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common sliares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at 2085 Baldwin Street, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 903-66 Ludger Bouchard inc.Notice is given that under Part 1 of the Com pan ics Act, letters patent, bearing date the 10th day of March, 1966, habe been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Ludger Bouchard, miller Thérèse Robert, housewife, wife separate as to property of the said Ludger Bouchard, ami Aimé Bouchard, annuitant, all three of St-Gédéon.county of Frontenac, for the following purposes: 2300 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril tUdil, US' année, n° la Faire affaires comme meuniers, sous le nom de « Ludger Bouchard inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à St-Gédcon, comté de Frontenac, district judiciaire de Beaucc.Le Sous-secrétaire de la province, KaVMONO DoCVILLE.1472Ô-0 1046-66 Itou chérie l'a pi ne au Iter Papineau Butchers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ixti des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de mars I960, constituant en corporation: Allan Marcus, avocat, 1545, McGregor, Montréal, Abel Selick, avocat, 1605, chemin Norway, Mont Royal, et Lucille Blagdon, secrétaire, fille majeure, 10437, IVAuteuil, Montréal, \\xtur les objet! suivants: Exercer le commerce de viande, volaille, fruits, légumes et tous autres produits, articles et inarcliaihli-.es se rapportant à l'épicerie, sous le nom de « Boucherie Papineau ltée \u2014 Papineau Butchers Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 390 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doc ville.14725 966-66 Boutique du soulier inc.Shoe Boutique Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Iaring date the 7th day of March, 1900, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incor|)orating: Allan Marcus, advocate.1545 McGregor, Montreal, Alx*l Selick, advocate, 1005 Norway Road, Mount Royal, and Lucille Blagdon, secretary, spinster of the full age of majority.10437 D'Auteuil.Montreal, for the following purposes: To deal in meats, poultry, fruits, vegetables and all other goods, wares and merchandise connected with the grocery business, under the name of \"Boucherie Papineau ltée \u2014 Papineau Butchers Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of si each and 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Mont real, judicial district of Montreal.Raymond Docville, Assistant Secretary of the Province.14725-o 966-66 Boutique du soulier inc.Shoe Boutique Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Fernand Joncas, trader 6820, 20th Avenue, Joseph Lacoursière, manager.10184 Iberville, both of Montreal, and Richard Joncas.purchaser.8975, 9th Avenue.St-Michel, for the following purposes: To deal in all kinds of shoes and leather articles, under the name of \"Boutique du soulier inc.\u2014 Shoe Boutique Inc.\", with a total capita! stock of 180,000, divided into 5.000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Mont real, judicial district of Montreal.Raymond Docville.Assistant Secretary of the Province.14725 589*66 Brujohn Properties Ltd.Notice is given that under Part 1 of the Companies Act.letters patent, bearing date the 27th day of January.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Kenneth Gates, advocate, 166 Woodside Crescent.Beaconsficld.Eleanor Robertson, 3041 Beaugrand Street, and Charmaim Huot.2239 Oxford Avenue, the latter two secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of \"Brujohn Properties Ltd.\", with a capital stock divided into 25,000 common shares without par value and 45,000 preferred shares of a par value of $5 each. QUEBEC OFFICIAI, GAZETTE, April 23, 1969, Vol.os, No.16 2291 Ix' liège social een issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Jean-Claude Dupont, chiropractor, Blanche Marchesseault, housewife, wife contractually separate as to property of said Jean-Claude Dupont, both of 80 St-Félix Street, Drummondville-West, and Francois Dupont, civil servant, 298 St-Marcel Street, Drummondville, for the following purposes: To exercise the oj>erations of a physical culture studio, under the name of \"Centre Dumar inc\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Drummondville, judicial district of Drummond.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 692-66 Jacques Charron construction ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Ix>i «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres 1 latentes, en «late du 1er jour de mars 1966, constituant en corporation: Jacques Charron, entrepreneur en construction, Jacqueline Bailly, ménagère, épouse contract uellement séparée de I liens dudit Jacques Charron, tous «leux de 1, rue Laurin, et Marc Charron, assistant-gérant, 8, rue Deschambault, tous trois de Ste-Thérèse, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom «le « Jacques Charron construction ltée», avec un capital total de $50,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.fx?siège social «le la compagnie est 1, rue Laurin, Ste-Thérèse, district judiciaire «le Terre-bonne.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.1 1725-0 818-00 Jacques Charron construction ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of March, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacques Charron, building contractor, Jacqueline Bailly, housewife, wife contractually separate as to property of sai«l Jacques Charron, both of 1 Laurin Street, and Marc Charron, assistant-manager, 8 Deschambault Street, all three of Ste-Thérèse, for the following purposes: To carry on business as a real estate ami construction company, under the name of \"Jacques Charron construction ltée\", with a total capital stock of 850,000, divided into 250 common shares of 8100 each and into 250 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 1 Laurin Street, Ste-Thérèse, judicial district of Terrebonne.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 818-06 I .e Club de chasse à tir de Québec Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi «les compagnies, l'administra\" leur «lu gouvernement «le la province a accordé des lettres patentes, en «late «lu 4e jour «le mars 1066, constituant en corporation sans capital-actions: Louis Rémillard.avocat.1109.Brown.Québec, Paul Morin.agent d'assurances, 1307.l'ontcnay, Ste-Foy, Kenneth Lachapelle, vétérinaire, 1635.Ranvoy/.é.Ste-Foy, Dr Claude Petitclerc, médecin, 3038, La Forêt.Ste-Foy.et Raoul Hunter.scUlteur, 470.Lemesurier.Québec, pour les objets suivants: Former et «liriger un club «le chasse et pro* mouvoir le sport en général, sous le nom «le Le Club «le «-basse à tir «le Québec ss.\\a> montant auquel sont limités les revenus annuels «les biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est «le 820.000.Le Club de chasse à tir de Québec Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day «>f March.1906.have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Louis Rémillard.advocate.1109 Brown, Quebec, Paul Morin.insurance agent.1307 Fontcnay, Ste-Foy.Kenneth Lachapelle.veterinarian.1(535 Hanvoy/é.Ste-Foy.Dr.Claude Petitclere.physician.3038 La Forêt, Ste-Foy, and Raoul Hunter, scultor.470 Lemesurier, Quebec, for the following purposes: To form and direct a hunting club, and t«> promote sports in general, under the name of \"Ix» Club «le chasse à tir «le Québec\".The amount to which the annual income from the immovable property which the corporation may acquire ami bold is to l>e limited, is 820.000. GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 23 avril 1960, 98* année, »° 10 2292 Ix* siège social de la corporation est à Québec, district judiciaire de Québec, Le Sous-secrf taire de la province.Raymond Douvillk.I4725-0 034-66 Club Optimiste Saint-Jean ine.Avis est donne qu'en vertu de la troisième partie «le la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de mars 1066, constituant en corporation sans capital-actions: Claude Payette, libraire, 222, 15e Avenue.Iberville, Guy Baraby, commerçant.561, Dorchester, et Jacques Rancourt, avocat.112, St-Jacques, ces deux derniers «le St-Jean, pour les objets suivants: Former une association pour développer «le toute manière l'Optimisme comme philosophie «le vie, sous le nom de « Club Optimiste Saint-Jean inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $100.000.Le siège social de la corporation est 112.rue St-Jacques.St-Jean.district judiciaire d'Iber-ville.Le Sous-secrêtaire de la province.Raymond Dorviu.k.14725-o 876*66 Comité de loisirs de Clarke City Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de mars 1966, constituant en corporation sans capital-actions: Narcisse Larouche, gérant de club social, P.-Walter Boudreault, gérant de magasin, Jean-Charles Déraspe, contremaître, Raoul Bilodeau, propriétaire de taxi, Guy Hould, comptable, Edmond-H.Boudreault, soudeur, et Jean-Louis Gélinas, constable, tous sept d'Arnaud (Clarke City), pour les objets suivants: Établir et exploiter un ou des centres de bien-être et loisirs, sous le nom de « Comité de loisirs de Clarke City ».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $200,000.Le siège social de la corporation est à Arnaud (Clarke City), district judiciaire de Hauterive.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.14725-0 1044-06 Comité des loisirs St-Cyrille-de-Wendover inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres-patentes, en date du 3e jour de février 1966, constituant en corporation sans capital-actions: Roy Walsh, journalier, Gélase Courchesne, commerçant, Hilarion Lemire, maître de poste, Edouard St-Cyr, garagiste, Edouard Allard, plombier, et Michel Verrier, agent d'assurance, tous six de St-Cyrille-de-Wendover, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de « Comité des loisirsSt-Cyrille-«le-Wendover inc.».The head office of the corporat ion is at Quebee, judicial district of Quebec.Raymond Dorviu.k.issistant Secretary of the Province, 14725 934.66 Club Optimiste Saint-Jean inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act.letters patent, bearing date the 3rd day of March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government «>f the Province to incorporate a corporation without share capital: Claude Payette, bookseller, 222, 15th Avenue.Iberville.Guy Baraby, tradii.501 Dorchester, and Jacques Rancourt.lawyer, 112 St-Jacques, the latter two ol \" St-John's, for the following purposes: To form an association to develop in every way Optimism as a philosophy of life, under tin name of \"Club Optimiste Saint-lean inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $100.000.The head office of the corporation is at 112 St-JacqUes Street.St.John's, judicial district of Iberville.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 876-66 Comité de loisirs de Clarke City Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Narcisse Larouche, social dub manager, P.-Waltcr Boudreault, store manager, Jean-Charles Déraspe, foreman.Raoul Bilodeau, taxi owner, Guy Hould, accountant.Edmond-H.Boudreault, welder, and Jean-Louis Gélinas, constable, all seven of Arnaud (Clarke City), for the following purposes: To establish ami operate one or several welfare and recreational centers, under the name of \"Comité de loisirs de Clarke City\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $200,000 The head office of the corporation is at Arnaud (Clarke City), judicial district of Hauterive.Raymond Dorviu.k.Assistant Secretary of the Province.14725 1044-0'i Comité des loisirs St-Cyrille-de-Wendover inc.Notice is given that under Part III of tin-Companies Act, letters patent, l>earing «late the 3rd day of February, 1906, have Im?cii issued by the Lieutenant-Governor of the Province, to incorporate a corporation without share-capital: Roy Walsh, labourer, Gélase Courchesne, trader.Hilarion Lemire, post master, Edouard St-Cyr, garage keeper, Edouard Allard, plumber, and Michel Verrier, insurance agent, all six of St Cyrille-de-Wendover, for the following purposes Organisation of recreation center, under the name of \"Comité des loisirs St-Cyrille-de-Wendover inc.\". QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23.1966, Vol, 98, No.16 22! 13 Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $50,000.Iaj siège social de la corporation est a St-Cyrille-de-Wendovcr, district judiciaire «le Drummond.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14726*0 160-66 (Compagnie Cemalian ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, l'administrateur «lu gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date «lu Se jour «le mars 1966, constituant en corporation: Raymond-G.Décary, avocat, 5014, Canterbury, Montréal, (*lau«le-E.Leduc, avocat, 105, Beverley, Mont-iîoyal, Jean (îuy, avocat, 5400.de Louisbourg, Montréal, et Cilles Bertrand, avocat, 5040, Decelles, Montréal, j>our les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «le placement, sous le nom «le «Compagnie Cemalian ltée >-, avec un capital total de $320,000, divisé en 100.000 actions ordinaires «l'une valeur nominale île 81 chacune et en 1,600 actions privilégiées d'une valeur nominale «le $100 chacune.Ix' siège social de la compagnie est à Laval, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.14725-0 1007-00 Conseil du Patronat du Québec inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie «le la l.oi «les compagnies, l'administrateur «lu gouvernement «le la province a accordé des lettres patentes, en date «lu 0e jour «le mars 1966, constituant en corporation sans capital-actions: Jean Girouard, avocat, 2575, Marie Le Neuf, Trois-Rivièrcs, Marcel-J.G.Beaumier, avocat, 101, 4e Avenue.(irand'Mère, et Hélène Baribeau, secrétaire, fille majeure, 110, rue Beauchemin, Cap-de-la-Madeleine, pour les objets suivants: Grouper en fédération les associations qui ^'occupent d'activités patronales au Québec, sous le nom «le « Conseil «lu Patronat «lu Québec inc.».Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est «le $500,000.Ia7 siège social «le la corporation est à Montrai, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.14725-0 3400-(i5 Dixon Van Lines (Montreal) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur «lu gouvernement de la province a accortlé des lettres patentes, en date du 8e jour de mars 1060, constituant en corporation: Reid Waring, administrateur, 1051, William London, province d'Ontario, Gérarc owned or held is to limited, is $60,000.The head office of the company is at St-Cyrille-de-Wendovcr, judicial «listrict of Drummond.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 460-66 Compagnie Cemalian Itce Notice is given that Under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of March, 1960, have liecn issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Raymond-G.Décary, advocate, 5014 Canterbury, Montreal, Claude-E.LedUC, advocate, 105 Beverley, Mount Royal, Jean Guy.advocate, 5400 «le Louisbourg, Montreal, and Gilles Bertrand, advocate, 5640 Decelles, Montreal, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Compagnie Cemalian ltée\" with a total capital stock of $320.000.divided into 160,000 common shares of a nominal value of 81 each ami 1,600 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Laval, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 1007-60 Conseil du Patronat du Québec inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 0th day of March, 1900, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Jean Girouard, advocate.2575, Marie Le Neuf, Trois-Rivières, Marcel-J.G.Beaumier, advocate, 101, 4th Avenue, Grand' Mère, et Hélène Baribeau, secretary, fille majeure, 110, Beauchemin St.Cap-de-la-Madeleine, for the following purposes: To group in federation the associations interested in patronal activities of Quebec, under the name of \"Conseil du Patronat «lu Québec inc.\".The amount to which the value of the annual revenue from the immoveable property which the corporati«m may own or acquire is to be limited is $500.000.The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 340045 Dixon Van Lines (Montreal) Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, lx?aring «late the 8th day of March, 1900, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Reind Waring, executive, 1051 William, London, Province of Ontario, Gérard Corlieil, barrister, 394 De Maricourt, LongUeuil, and Harold Hinton, manager, 217 Main Street, Exeter.Province of Ontario, for the following purposes: To carry on the business of a transportation company, under the name of \"Dixon Van Lines (Montreal) Limited\", with a total capital stock of $40,000, oîvided into 1,000 common shares GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril 1966, OS' année, n° 16 valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Ix\" siège social «le la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.1472') 086-66 of a par value of $10 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Mont real, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.1472Ô-0 986-6(1 Domaine Mont-Joly du Lac Pause inc.Mont-Joly's Estate of Lake Pauze Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a acconlé des lettres patentes, en date du 7e jour de mars 1966, constituant en corporation: Gaston Roy, garagiste, 41, 4e Avenue, Marcel Laçasse, industriel, ô, rue Collin, et Jean-Paul Chartrand, 374, Grande-Cote* tous trois de Ste-Thérèse-Ouest, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «l'immeuble et de construction; exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de « Domaine Mont-Joly du Lac Pauzé inc.\u2014 Mont-Joly's Estate of Lake Pauze Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Ste-Thérèse-Ouest, district judiciaire de Terrebonne.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14725-0 920-66 Domaine Mont-Joly du Lac Pauzé inc.Mont-Joly's Estate of Lake Pauze Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of March, 1906, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating Gaston Roy, garage keeper, 41, 4th Avenue, Marcel Laçasse, Industrialist, 5 Collin Street, and Jean-Paul Chartrand.374 Grande-Cote, all three of Ste-Thérèse-West, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, to operate hotels, tavern-, inns and restaurants, under the name of \"Domaine Mont-Joly du Lac Pauzé inc.\u2014 Mont-Joly-Estate of Lake Pauze Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Stc Thérèse-West, judicial district of Terrelxmne.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.1472Ô 920-66 Dream Lounge Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement «le la province a accordé des lettres patentes, en «late du 4e j«>ur «le mars 1966, constituant en corporation: Toni Cava.Comptable, Evelyn Shatilla.ménagère, épouse dudit Toni Cava, tous deux «le 95, Trenton.Mont Royal, et William Sklar.industriel, 5120, «le la Peltrie.Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le restaurateurs, sous le nom «le « Dream Lounge Inc.», avec un capital total de $40.000, «livisé en 400 actions ordinaires «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétairc de la province.Raymond Dorviu.k.14725 5115-65 Dream Lounge Inc.Not,ice is given that under Part 1 of the Companies Act.letters patent, bearing date the 4th day of March, 1900.have been issued by the Administrator «>f the Government of the Province, incorporating: Torn Cava, account an I.Evelyn Shatilla.housewife, wife of the said Toni Cava, both of 95 Trenton.Mount Royal, and William Sklar, industrial, 5120 de la Peltrie, Montreal, for the billowing purposes: To carry on the business of restaurateur^, under the name of \"Dream Lounge Inc.\".with a total capital stock of $10.000.divided into 400 common shares «>f $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond DouVILLE, Assistant Secretary of the Province.14725-0 ôllô-ii.': Dubcau & Giroux Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la I^oi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes, en «late du 1er jour «le mars 1966, constituant en corporation: Stanley Dubeau.David Bubeau et Léo Dubeau, tous trois hommes d'affaires, «le 4650, avenue Doherty.Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce «le fourrures, peaux, peaux crues, cuirs et tissus, sous le nom de « Dubcau & GiroUX Inc.», avec un capital total de $40.000.divisé en 200 actions Ordinaires «l'une valeur au pair «le $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $100 chacune.I.c siège social «le la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Montréal.I.e Sous-secrêtaire de la province.Raymond Dorviu.k.14725 856-66 Dubeau & Giroux Inc.Notice is given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 1st day of March.1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Stanley Dubcau.David Dubcau and Léo DubeaU, all three businessmen, of 4650 Doherty Avenue.Montreal, for the following purposes: To deal in furs, skins, hides, leathers and mate rials, under the name of \"Dubeau & Giroux Inc.\".with a total capital stock of $40.000.! $100 each and 200 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond DouVILLB, Assistant Secretary of the Province.14725-0 858-66 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 1900, V4.98, So.10 2295 Kobcrt J.Dumoulin Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en «late du Se jour de mars 1906, constituant en corporation: Harold W.Ashcm-inil, avocat, 5011, rue Dolhcau, Montréal, Stanley H.Sinister, avocat, .r)f>20, rue Aslidale.Côte-St-LuC, et .Ion Kosorwicli, avjx-at, 2KM) < inert in, St-Laurent, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie «le placements, sous le nom de « Robert .1.Dumoulin Investment Corp.avec un capital total «le $40,000, «livisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le Si chacune et 20,000 actions privilégiées «l'une valeur au paire de SI chacune.Le si«'gc social de la compagnie est 3150, rue Sartelon, St-Laurent, district judiciaire vinc«' a accordé des lcttr<-s patentes, en «late «lu 9e jour de mars 1000.constituant en corporation: (ïuy Lacoste, ¦uS~.avenue Vendôme, Bernard-C.Forest, 3760, avenue Harvanl.tous «leux notaires, et Solange Julien, secrétaire, fille majeure.5300.avenue H rôdeur, tous trois «le Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme elect riciens, sous le nom de « Albert Dvottc & fils inc.», avec un capital total «le $150,000, divisé en 10.000 actions ordinaires «l'une valeur nominale de SI chacune et en 7,000 actions privilégiées d'une valeur nominale «le $20 chacune.Le siège social de la compagnie est 7348, rue St-Hubcrt, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Dor villi:.! 1725-.884-00 Will Eagle Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé «les lettres patentes, en date du 20e jour «le «lécembre 1005, constituant en corporation: Arthur Carey Strafford Stead, avocat, 275, avenue Dorval.Dorval, Ina Mason, teneuse de livres, veuve non remariée d'Allxjrt Ethvard Mason, 187, chemin Cap St-\u2022lacques, Pierrefonds, et Phyllis Elizal>eth Russell, -ecrétaire, épouse sepam?de biens «le James ( iordon Russell, en vertu des lois de la province ¦ le la Nouvelle Ecosse, 138, 5e avenue, Pincourt, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux et «le constructeurs, sous le nom de « Wilf Eagle Limited », avec un capital-actions «livisé en 2,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 05, avenue Doncgani, Pointe-Claire, «listrict judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11725 5704-05 Robert J.Dumoulin Investment Corp.Notice is given that Under Part I «»f tin-Companies Act, letters patent, bearing «late the 8th day of March, 1000, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Harold \\V.Ashcmmil, advocate, 5911 Dolbeau Street, Montreal, Stanley R.Sinister, advocate, 5520 Ashdale Street, Cote-St-Luc, and Jon Kosorwich, advocate, 2100 Guertin, St-Laurent, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of « Robert J.Dumoulin Investment Corp.», with a total capital stock «>f $40,000, divided into 20,000 common shares of the par value of SI ea«li and 20.000 preferred shares «>f the par value «>f SI each, The head office of the company Is at 3150 Sartelon Street, St-Laurent, judicial district of Montreal.Raymond Dor villi;.Assistant Secretary of the Province.14725-0 1052-66 Albert Dyotte & fils inc.Notice is given that under Part 1 of the Companies Act.letters patent, bearing date the 0th day of March.1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Guy Lacoste, 3787 \\'en«l«*)ine Ave.Reruard-C.Forest.3700 Harvard Ave., both notaries, and Solange Julien.secretary, fille majeure, 5300 Brodeur Ave., all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as electricians, under the name of \"Albert Dyotte & fils inc.\", with a total capital Stock of $150,000, divided into 10,000 common shares <f a nominal value of S20 each.The head office of the company is at 7348 St-IIubert St., Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dot villi;.Assistant Secretary of the Province.14725 884-66 Wilf Eagle Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing «late the the 20th day of December, 1005, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Arthur Carey Strafford Stead, advocate, 275 Dorval Avenue, Dorval, Ina Mason, l)ookkeeper, unremarried widow of Albert Edward Mason.187 Cap St-Jacques Road.Pierrefomls, and Phyllis Elizabeth Russell, secretary, wife separate as to property of James Gor-«lon Russell, in acconlance with the laws of the Province of Nova Scotia, 138, 5th Avenue, Pin-court, for the following purposes: To carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Wilf Eagle Limited\", with a capital stock divided into 2,000 common shares without par value ami 2,000 preferre ltée », avec un capital total «le §70.000.«livisé en 800 actions ordinaires «le $100 chacune et en 450 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Jacques-Cartier, «listrict judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la prorince.Raymond Douville.14725-0 1041-66 Emile Faucher inc.Avis est donné qu'en vertu «le la premier»- partie de la Loi «les compagnies, l'administrateur du gouvernement «le la province a accordé «les lettres patentes, en «late «lu Se jour «le mars 1966, constituant en corporation: Emile Faucher.industriel.Lucienne Thcrrien.ménagère, épouse séparée «le biens dudit Emile Faucher, tous «leux «le 94, Johnson.Coaticook, et Cécilien Lapointe.contremaître.17S.Bcaulé.Coaticook, pour les objets suivants: industrie et commerce «lu bois, sous le nom «le « Emile Faucher inc.», avec un capital total «le 840.000, «livisé en 400 actions ordinaires «le §100 chacune.Le siège social «le la compagnie est 402.rue Merrill.Coaticook, district judiciaire «le St- François.Le Sous-Secrétaire de la province.Raymond Doiville.14725-0 748-66 G.M.T.Stencil Cutting Machine Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Ix>i «les compagnies, l'administrateur «lu gouvernement de la province a acconlé «les lettres patentes, en date du 3e jour de mars 1900.constituant en corporation: Jacques Thébcrge, I.cs Entreprises Del-Champ inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of March, 1900, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Alain Belzile, Pierre Cardinal, both chartered accountants, of 2345 Bélanger, Montreal, and Guy Tru«lel, manager, 20 Terrasse Royale, Rejientigny, for the follow ing purposes: To carry on business as grocers, under the name of \"Les Entreprises Del-Champ inc.\".with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 3565 Monsclet St., Marché Dun, Montreal-North, judicial «listrict of Montreal.Raymon d DoUVl lle, Assistant Secretary of the Province.14725 72 l-i io Les Entreprises Halo ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 14th day of March.1966, have been issued by the Administrator of the Government «>f the Province, incorporating: Tibor J.Halo, technician in architecture.95 Frnncois-Gauthier St.Boucherville.Sandor B.Halo, engineer.251 Martin St., Jacques-Cartier, and Georges Halo.interior decorator, 1000 Pasteur St.Brossard, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Les Entreprises Halo ltée\", with a total Capital stock of $75,000, divided into 300 common shares of 8100 each and 450 preferred shares of 8100 each.The head office «>f the company is at Jacques-Cartier, judicial «listrict of Montreal.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.1472Ô 1041-60 Emile Faucher ine.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of March.1986, have been issued by the Administrator of the Government of tin Province, incorporating: Emile Faucher, industrialist, Lucienne Thcrrien.housewife, wife separate as to property of said Emile Faucher, both of 04 Johnson.Coaticook.ami Cécilien Lapointe, foreman.17S Beaulé.Coaticook, for the following purposes: The industry ami business dealing of wood, under the name of \"Emile Faucher inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company is at 402 Merrill Street.Coaticook.judicial «listrict «>f St.Francis.Raymond Doiville.Assistant Secretary of the Province.14725 748-6(1 G.M.T.Stencil Cutting Machine Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing «late the 3rd day of March, 1900, have been issued by the Administrator of the Government of tin-Province, incorporating: Jacques Thél>erge.355 QUEBEC OFF 1 CEIL GAZETTE, April §8, I960, Vol.98, So.Hi 22! 17 365, lléroux, Gerald Caron, 301* 4e avcmic, tous ilcux industriels, dThcrvillc.Anthony Gaspari.7:155, L'Acadic, app.404.et John Gaspari, 133A, Foucher, ees deux derniers commerçants, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme ouvriers en métaux, sous le nom de «G.M.T.Stencil Cutting Machine Co.Ltd.\".avec un capital total de 8100,000, divisé en 500 actions ordinaires de SI00 chacune et en 500 actions privilégiées «le S100 chacune.l«o siège social de la compagnie est à Montréal, district Judiciaire de Montréal.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Dou ville.il725-o 681-66 Great Whale River Community Association Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement «le la province a acconlé «les lettres patentes, en «late du 4e jour «le mars 1966, constituant en corporation sans «\u2022apital-actious: Thomas Stuart Gillespie, West mount.Raymond Crevier, Montréal, Paul Fortin, Montréal.David Henry Holland, St-Lambert, tous quatre avocats, Krnest William Mockridge, gérant.St-Lambert, Charles Kric Humphrey, teneur «le livres.Verdun, Clifford George Meek, comptable, Guy Ambrose Miller, commis.( !olin RichardChisholm commis, et Theodore William Martinson, teneur de livres, ces quatre derniers «le Montréal, pour les objets suivants: Organiser et gérer une association à toutes fins sociales, culturelles, récréatives, athlétiques et sportives, sous le nom «le « Great Whale River Community Association Ltd.».Le montant auquel est limité le revenu annuel de la propriété immobilière «pie la corporation peut détenir est «le 850,000.Ix- siège social «le la corporation est à village «le Postc-de-la-Bnlcine.«listrict judiciaire artie de la Loi des compagnies, le lieutenant - Héroux, Gérahl Caron.201, 4th Ave., both imlustrialists.of Iberville, Anthony Gaspari 7355 L'Aj-ajlie.Apt.404.and Jonh Gaspari.8433A Foucher.the two latter traders, «»f Montreal, for the following purposes! To carry on business as natal workers, under the name «>f \"G.M.T.Stencil Cutting Machine Co.Ltd.\", with a t«»tal capital stock «>f $100,000, divided into 500 common shares «tf $100 each ami 500 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Montreal.judicial «listrict of Montreal.Raymond Doi villk, Assistant Secretary of the Province.14725 681-00 Great Whale River Community Association Ltd.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 4th day «>f March.1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Thomas Stuart Gillespie, Westmount, Raymond Crevier, Montreal, Paul Fortin.Montreal, David Henry Holland.St-Lambert.all four advocates, Ernest William M«>ckrif Montreal.f«>r the following purposes: To operate ami manage an Association for all social, cultural, amusement, athletic ami s|M)rting purposes, under the name \"Great Whale River Community Association Ltd.\".The amount t«> which the annual revenue from the immoveable property which the corporation may hold is to Ik- limited, is $50.000.The head office of the corporation is ait Village «)f Postc-dc-la-Baleinc.judicial district of Hautc-rive.Raymond Doiville.Assistant Secretary of the Province.14725-o 900-66 lis Immeubles G.B.G.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, !)earing tlate the 10th ert, housewife, wife separate as to property of the said Gaston Guill>ert, the two latter of 42 Adrien St., Repentigny, for the following purposes: To carry on business as a real estate ami construction company, under the name of \"Les Immeubles G.B.G.inc.\", with a total capital stock of $40,000, «livided into 2,000 common shares of a nominal value of $10 each and 2,000 preferre«l class \"A\" shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Repentigny, judicial district of Joliette.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 1009-00 Institut de Réhabilitation Richelieu pour les enfants handicapés, inc.Notice is given tliat under Part III of the Companies Act.letters patent, bearing date the 2298 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 96 mil 196$, 98* annk, n* w gouverneur de la province a accorde des Ici 1res patentes, en date du 10c jour de novembre 19('>f>, constituant eu cori>oration sans capital-actions: Albert Dumont, comptable, 88, Moncion, Royal Gauvin, imprimeur, 92, Prud'Hoiumc, Marcel (îraml'Maltrc, ingénieur, 20, Moncion, Rolicrt-J.Lacbappelle, secrétaire exécutif du Conseil Economique du Canada, 10, Cayer, Dr .Icau-Kudcs Lament, pédiatre, 8, Cayer, Dr Paul-André Meilleur, médecin interne, 48, Moncion, Dr Guy Morissettc, ortlio|M;diste, 22, Thibault, Michel Pharaud, avocat, 33.Jolicoeur, et Jacques Vin-son, optométliste, 77, Prud'llonune.tous neuf île Hull, |M)ur les objets suivants: Etablir et administrer une clinique i>our les enfants handicapés, sous le nom de « Institut de Réhabilitation Richelieu |M)iir les enfants handicapés, inc.I.e montant auquel sont limités les biens immobiliers que la cor|x>ratiou jn-ut acquérir et |x>ssé-der, est de 80,000,000.Le siège social de la corporation est à Hull, district judiciaire de Hull.Le 8ùlU secrétaire de la province, Raymond Doiviu.k.I472.\")-o 4936418 Islund Associates Inc.Les associés des Iles inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies.l'administrateur «lu gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du Se jour de mars 1000, constituant en corporation: Murray Lapin, avocat et conseil en Loi de la reine, 107.chemin Kdgchill.West mount, Norman May.avocat.574N, Kldriilge.( otc-St-Lue, et Avruin Ruhinger.avocat, 4530, Côte-des-Neiges, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, bous le nom de « Island Associates Inc.Les associc's des lies inc.avec un capital total de 840.000.divisé en 10.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 81 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège sixial de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sons-secrétuirc de la province, Raymond Doivii.i.i:.14725 988416 1 lalcaii Investment Corporation Corporation d'investissement Italian Avis est «humé qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, radministrâleur «lu gouvernement de la province a accordé «les lettres patentes, en date du Se jour «h' mars 1900, constituant en corporation: Sergio F.Cruciani, industriel.Voa 1 (ïoiran 23, Rome, Italie, Joseph Di Clementi, avtx-at, 4300, avenue Western, app.030, Westmount, et J.Giacomo Di Michèle, agent «le ventes, 2145, Champ Fleury, Laval, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie «le placements, sous le nom de « Italcan Investment C«>rporati«>n \u2014 Corporation d'investissement Italcan «, avec un capital-act ions «livisé en 1.000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège s«x-ial «le la compagnie est 2015, rue Drummond, suite 750, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le S ou.t-secret a ire de la province, Raymond Douvillk.14725 1053-00 10th day of November, 1005, have been issued by the Administrator of the Government of tin-Province to in«\"or|)orate a corporation without share capital: All>ert Dumont, accountant, 33 Moncion, Royal Gauvin, printer, 92 Prud' Homme, Marcel Graml'Mattre, engineer, l'u Moncion, Robert-J.Lachapelle, executive-secre-tary of the Economic Council of Caiuula, iii Cayer, Dr.Jean-Eudea Lamont, podiatrist, s Cayer, Dr.Paul-André Meilleur, intern, 48 Moncion, Dr.(Juy Morissettc, ortbopae«list, 22 Thibault, Michel Pharaud, lawyer, 33 Joliooeur, ami Jac«|iies Vinson, optometrist, 77 Prud Homme, all nine of Hull, for the following pur |M>ses: To establish and administer a clinic for hand! capped children, under the name of \"Institut de Réhabilitation Richelieu |x>ur les enfant - handicapés, inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation maj acquire and hold is to Ik* limited, is $5,000,00(1.The bead office of the corporation is at Hull judicial district of Hull.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 4986-65 Island Associates Inc.I ,<-.s associés des Iles inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date tin 8th day «»f March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Murray Lapin, advo cate and Queen's Counsel, 167 E«lgehill Road.Westmount.Norman May, advocate, 6748 Eldridge, C6te43t-Luc, ami Avrum Rubinger, advocate, 4680 Côte-des-Neiges, Montreal, for the following purposes: To carry on the business «>f restaurateurs, under the name of \"Island Associates Inc.Les associés «les lies inc.\", with a total capital stock of 840.000.divided into lO.(KK) common shares of the par value of $1 each and 3,000 preferred shares of the par value of $10 each.The bead office of the company is at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-o 983416 Italcan Investment Corporation Corporation d'investissement Italcan Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 8th day of March, 1900, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Sergio F.Cruciani.industrialist, Via 1 (ïoiran 23, Rome.Italy.Joseph Di dementi, advocate, 4300 Western Avenue, Apt.030, Westmount, and J.Giacomo Di Michèle, sales agent, 2145 Champ Fleury.Laval, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Italcan Investment Corporation \u2014 - Corporation d'investissement Italcan\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without par value.The head office of the company is at 2015 Drummond Street, suite 750.Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-0 10634)6 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.April S3, 1000, Vol, ON, So.10 2200 Jurado Investments Ltd.Avis est doiulé qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé des lettres patentes, en date du 27e jour de janvier I960, constituant en corporation : Melvin Hotliman, avocat, 688, avenue Roslyn, Westmount, Alan Golden, avocat, 4067, avenue Vendôme, Montréal, Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, 1660, avenue Madison, Montréal, et Kleanor Johnson, secrétaire, fille majeure, 5327 A, Prince de Galles, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de « Jurado Investments l.td., avec un capital total de $40.000, divisé en 1.(100 actions ordinaires de 110 chacune et 30,000 actions privilégiées de Si chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doivillk.14725 407-00 Jurado Investments Ltd.Notice is given that under Part I of the Compagnies Act, letters patent, hearing date the 27th day of January, 1000, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Melvin Rothman, advocate, 638 Roslyn Avenue, Westmount, Alan Golden, advocate, 4007 Vendôme Avenue, Montreal.Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, 4650 Madison Avenue, Montreal, and Kleanor Johnson, secretary, fille majeure, 5327 A Prince of Wales.Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Jurado Investments Ltd.\".with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.1472Ô-0 467-66 L & W Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de mars 1900, constituant en corporation: David Chin, ingénieur, 0081, nie Hutchison, Montréal, Donald Lee, marchand, 4055, rue Hutchison, Montréal, Hem Wing Lee, ingénieur, 3915, rue St-Urbain, Montréal, et Jun Kin Wong, ingénieur, 3528, rue Jeanne-Mance, Montréal, j)our les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom de L & W Investments Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 5105 ouest, rue Sherbrooke, suite 204.Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Doivillk.11725 1001-66 L & W Investments Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 9th day of March.1900.have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: David Chin, engineer.0081 Hutchison Street, Montreal, Donald Lee, merchant, 4055 Hutchison Strect.MtMitreal, Hem Wing Lee, engineer.3915 St.I'rbain Street, Montreal, and Jun Kin Wong, engineer, 3528 Jeanne-Mance Street, Montreal.f«>r the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"L & W Investments Inc.\".with a total capital Stock of $40,000.«livi«lc«l into 100 common shares of S100 each ami 300 proferrc«l shares of 8100 each.The hea«l office of the company is at 5105 Sherbrooke Street West, Suite 204.Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dor villi:, Assistant Secretary of the Province.14725-0 1001-00 Laroche draperies (Sorel) inc.Avis est donné qu'en versu «le la première l'artie «le la Loi «les compagnies, l'administrateur du gouvernement «le la province a ace«>rdé des let t res patentes, en «late «lu 10e jour «le mars 1900, constituant en corporation: Denis Laroche, commerçant, France Lussier, ménagère, épouse séparée «le biens dudit Denis Laroche, tous deux de 430, Bonaventure, Sorel, et Biaise Simoneau.agent d'assurance, 4095, Frontenac.Douvillc.pour les objets suivants: Paire le commerce «le «Iraperies, ritleaux, couvre-lits, coup«>us et autres tissus, sous le nom de « Laroche tlrajH-ries (Sorel) inc.».avec un capital total de $40,000, «livisé en 200 actions ordinaires «le $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie est 53D.rue Georges, Sorel.district judiciaire de Richelieu.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Doivillk.11725-0 993-00 Laroche draperies (Sorel) inc.Notice is given that under Part I «>f tin-Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of March, 1000, have been issued by the Administrator of the Government «>f the Province, incorporating: Denis Laroche, trader, France Lussier.housewife, wife separate as t«> property of said Denis Laroche, both of 430 Bonaventure, Sorel.and Blaise Simoneau, insurance agent, 4095 Frontenac.Douville.for the following purposes: To deal in draperies, curtains, bed-spreads, coupons ami other fabrics, under the name of \"Laroche draperies (Sorel) inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each ami into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 531) Georges Street.Sorel.judicial «listrict of Richelieu.Raymond Dor villi:.Assistant Secretary of the Province.14725 093-00 2300 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril 19110, 98' année, n° 10 Local Metal & Waste Ltd.Avis est donné qu'eu vertu de lu première parlie «le la Loi «les compagnies, l'administraicur «lu gouvernement «h- la province a accordi* des lettres patentes, en date «lu 7e jour «le mars 1060, constituant en corporation! Mortimer .1.Constant! ne, avocat, 425, avenue Hudson, Leonard Sinmoc, avocat, 27S7, Bcnjamin-Sultc, «-t Bessie Peters, secrétaire, épouse séparée «le biens «le Dave Peters, 3805, avenue Dupuis.tous trois de Montréal, pour les objets suivants-.Faire le commerce de produits de reltut et débris de métaUX «le toutes sortes, sous le nom «le « Local Metal & Waste Ltd., avec un capital total «le $10.000.divisé en 1.000 actions ordinaires «le S10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $io chacune.Ix' siège social «!«' la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillb.1472.') 071-00 Local Metal & Waste Ltd.Notice is given that initier Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 7th day of March, 1066, have been issued by the Administrator of the Government of the Provint <¦.incorporating: Mortimer J, Constantine, advo.cate, 425 Hudson Avenue.Leonard Bimcoe, advocate, 27S7 Benjamin-Suite, and Bessie Peters, secretary, wife separate as to property of Dave Peters, 3805 Dupuis Avenue, all titrée of Montreal, for the following purposes: To deal in waster products and scrap metals of all kinds, under the name of \"Loeal Metal & Waste Ltd.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 1.000 common shares of 810 each and 3.000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial «listrict «»f Montreal.Raymond DouVILLE, Assistant Secretary of the Province.14725-0 071-r,ii Les Loisirs de Tciiitagama inc.Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie de la l^oi des compagnies, l'administrateur «lu gouvernement «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 1 le jour «le mars 1000, constituant en corporation sans capital-actions: Yvette Simard.ménagère, épOUSe de Robert Simard, Lucie Morel, ménagère, épouse «le Jean-Marie Maltais, Rose-Y.Girard, ménagère, épouse de Gaston Tremblay, Gisèle Du- four, ménagère, épouse tic Gérard Maltais, et Arthur Morel, journalier, tous cinq «le Notrc-Dame-du-Rosairc.municipalité de Labrec<|iic, pour les objets suivants: L'organisation «les loisirs, sous le nom «le « Les Loisirs de Tchitagama inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de 850,000.Le siège social de la corporation est à Notre-Damc-du-Rosairc, municipalité de Labrecque, «listrict judiciaire «le Cbicoutimi.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.14725-0 083-00 Les Loisirs de Tchitagama inc.Notice is given that under Part III of tin-Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of March, 1000, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Yvette Simard, housewife, wife of Robert Simard, Lucie Morel, housewife, wife of Jean-Marie Maltais, Rose-Y.Girard, housewife, wife of Gaston Tremblay, Gisèle Dufour.housewife, wife of Gérard Maltais, ami Arthur Morel, labourer, all five of Notre-Dame-du- Rosaire, municipality of Labrecque, for tIn-following purposes: The organization of a recreational centre.Under the name of \"Les Loisirs «le Tchitagama inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire ami hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation is at Notre -Dame-Du-Rosaire, municipality of Labrecque, judicial district of Cbicoutimi.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 683-66 M.& M.Hobby limitée Avis est donné «m'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date «lu 7e jour «le mars 1906, constituant en corp«>ration: Henri Gauthier, industriel, 6678, rue des Ecores, Montréal, Maurice Coutu, vendeur, 16001, boulevard Ste-Croix, Pierrefonds, et Martial Paré, vendeur, 380, rue Charron, app.G, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce «le jouets, nouveautés, articles «le marotte (hobby), ameublements, quincaillerie et de toutes sortes «le spécialités connexes, sous le nom de « M.& M.Hobby limitée », avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Pierre-fonds, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.14725-o 704-06 M.& M.Hobby limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Henri Gauthier, industrialist, 0678 des Êcores Street, Montreal, Maurice Coutu, salesman, 16001 Ste-Croix Boulevard.Pierrefonds, and Martial Paré, salesman, 380 Charron Street, Apt.6, Montreal, for the follow ing purposes: To deal in toys, novelties, hobby articles, furniture, hardware and all kinds of specialties connected with these, under the name of \"M.& M-Hobby limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of |100 each.The head office of the company is at Pierre-fonds, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 704-01- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 19G(!, Vol.98, No.16 2301 Magasin Continental (Du Lac) ltée Continental Store (Du Lac) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date «lu 2e jour «le mars I960, cons* tituant en corporation: Jacques Gagnon, 837, l'ère-Champagnat, Paul-Emile Normand, 734.me Turgeon, tous deux comptables, et Marthe Desmeules, secrétaire, OU»' majeure, 544, rue Dclagc, tous trois «le Chicoutimi.pour les objets suivants: Faire le commerce «le toutes marchandises généralement vendues «lans un magasin à rayons, sons le nom de « Magasin Continental (Du Lac) ltée \u2014 Continental Store (Du Lac) Ltd.avec un capital total de 842.000, «livisé en 2.000 actions ordinaires «!«\u2022 $10 chat-une.2,000 actions privilégiées classe « A «le 810 chacune et en 2,000 actions privilégiées classe « B » «le $1 cha-cune.Le siège social de la compagnie est à Chicoutimi.district judiciaire de Chicoutimi.I.e Sous-srcrétuire de la province.Raymond Docville.11725-0 864-66 Magasin Continental (Du Lac) ltée Continental Store (Du Lac) Ltd.Notice is given that umler Part I of the Companies Act, letters patent, hearing «late the 2nd day of March, 1066, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: .la«'<|iies Gagnon, N37 Père-Champagnat, Paul-Emile Normand, 734 Turgeon Street, both accountants, and Marthe Desmeules, secretary, fille majeure.544 Delage Street, all three of Chicoutimi.f«>r the following purposes* To «leal in all kinds of merchandise generally sold in a department store, umler the name of \"Magasin Continental (Du Lac) ltée \u2014 Continental Store (Du Lac) Ltd.\", with a total capital stock of 842,000, divided into 2,000 common shares of $10 each, 2,000 preferred class \"A\" shares of $10 each ami into 2.000 preferred class \"B\" shares of $1 each.The head office of the company is at Chicoutimi.judicial «listrict of Chicoutimi.Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.14725 804-00 Magasin Guy inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes, en «late «lu 24e jour de février 1966, constituant en corporation: Guy Vachon.épicier.412.St-Michel, .lompiière, .loseph-Antoine Vachon, épicier, et Jacqueline Vachon, secrétaire, fille majeure, ces «loux derniers «le 671, boulevard St-Ignace.Chicoutimi.pour les «>hjets suivants: Faire affaires comme épiciers, sous le nom oe Magasin Guy inc.», avec un capital total «le $40,000, «livisé en 200 actions ordinaires «1 \"une valeur nominale de $100 chacune, 1.000 actions privilégiées classe « A » d une valeur nominale de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées classe B » d'une valeur nominale «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 100, rue Angers, .hnupiièrc.«listrict judiciaire de Chicoutimi.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doivillk.14725-0 610-66 Magasin Guy inc.Notice is given that umler Part I of the Compagnies Act, letters patent, bearing date the 24th day of February.1066, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Guy Vachon, grocer, 412 St-Michel.lompiière, .loseph-Antoine Vachon, grocer, ami Jacqueline Vachon, secretary, fille majeure, the two latter of 071 St-Ignacc Blvd., Chicoutimi, for the following purposes: To carry on business as grocers, under the name of \"Magasin Guy inc.\", with a total capital stock «>f $40.000.divided into 200 common shares of a nominal value of $100 each, 1.000 preferred class \"A\" shares of a nominal value of $10 each and 1.000 preferred class \"B\" shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at 190 Angers St.Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.14725 010-00 Marché Lachance inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a acconlé «les lettres patentes, en date du 7e jour de mars 1900, constituant en corporation: Nazaire Lachance, homme «l'affairés, Florence Nazaire, ménagère, épouse séparée «le biens dudit Nazaire Lachance, et dûment autorisée par lui aux fins «les présentes, tous deux «le 1261, Jean-Talon est, Montréal, et André Lachance, homme «l'affairés.249.De Blois, Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers-bouchers, sous le nom de « Marché Lachance inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 75,000 actions ordinaires «le SI chacune et en 7,500 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-sécrétaire de la province, Raymond Doivillk.14725-0 1028-00 Marché Lachance inc.Notice is given that umler Part I of the Companies Act.letters patent, bearing «late the 7th oration sans capital-actions: James Laing, surveillant des ventes, 577, 87e avenue, bavai, Larry West, officier technique, 7900, Desvendenne, Anjou, Jerry Forrest, trésorier, 50, avenue Stream, Dorval, William Falls, agent de service de l'immigration, 709, avenue Campliell, Greenfield Park, et Richard Joseph Connor, courtier en immeubles, 107, rue Charles, Pointe-Claire, pour les objets suivants: Préserver et perpétuer les associations et les traditions du « Royal Regiment of Canadian Artillery », sous le nom de «Montréal: Royal Regiment of Canadian Artillery « Number One Club».be montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la cor|)oration peut posséder OU détenir est de 8100,000.Le siège social de la corporation est 4000, avenue Lacombe, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doivillk.11725 5340-05 Murray Hill Equity Ventures Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en daet du 7e jour de mars 1900, constituant en corporation : Isidore M.Bobrove, avocat et conseil en Loi de la reine.5705, Côte-Sl-Lue, Hampstead, Nina Krolik, secrétaire, fille majeure, 5730, Esplanade, Montréal, et Jack H.Uobrove, avocat, 5015, avenue Cork, Côte-St-Luc, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de « Murray Hill Equity Ventures Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 39,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.14725 968-66 New Dream Lounge Bar Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de mars 1966, constituant en corj)oration: Seymour Luter-man, étudiant en droit, 7920, chemin Côte-St-Luc, Côte-St-Luc, Micheline Desjatnyk, 12, ( 'oolbreeze, Pointe-Claire, et Susan Curtis, 4035, Clanranald, Montréal, ces deux dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de « New Dream Lounge Bar Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 30,000 actions ordinaires de $1 chacune et 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrêtaire de la province, ' Raymond Douvillk.14725 970-66 Montreal: Royal Regiment of Canadian Artillery \"Numbers One\" Club Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, hearing date the 6th day of December, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to iueiirpurat ccll Avenue, Greenfield Park, and Richard Joseph Connor, real estate broker, 107 Charles Street, Pointe-Claire, for the following purposes: To preserve and perpetuate the associations and traditions of the Royal Regiment of Canadian Artillery, under the name of \"Montreal: Royal Regiment of Canadian Artillery \"Numbers One\" Club\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess or hold is to'l>e limited, is $100,000.The bead office of the corporation is at 4600 Lacombe Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-o 5340-65 Murray Hill Equity Ventures Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, l>earing date the 7th day of March, 1066, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Isidore M.Bobrove, advocate and Queen's Counsel, 5765 Côte St-Luc, Hampstead.Nina Krolik, secretary, spinster of the full age of majority, 5730 Esplanade, Montreal, and Jack B.Bobrove, advocate, 5015 Cork Avenue, Côte-St-Luc, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Murray Hill Equity Ventures Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each and 30,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymon d Douvillk, .Issistant Secretary of the Province.14725-0 968-66 New Dream Lounge Bar Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of March, 1966, have l>een issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Seymour Luterman, law-student, 7920 Côte-St-Luc Road, Côte-St-Luc, Micheline Desjatnyk, 12 Coolbreeze, Pointe-Claire, and Susan Curtis, 4035 Clanranald, Montreal, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, under the name of \"New Dream Lounge Bar Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 30,000 common shares of $1 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-0 970-60 2304 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.28 avril 1900, 98' année, n° 16 E.Normand inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 10e jour «le mars 1900, (instituant en corporation: Paul Langlais, voyageur et représentant, Jeannine Caron, ménagère, épouse séparée de bîcni dudit Paul Langlais, tous deux «le 2923, «le C'ourcelles, Ste-Foy, et {-'.milieu Martel, comptable agr«*é, 17, «le la Savoie, Courville, |x>ur les objets suivants: Faire le commerce «le toutes espèc.s d'articles et marchandises qui font généralement l'objet «l'un commerce «l'épicerie, sous le nom «le « E.Normand inc.».avec un capital total de §20,000, «livisé en 100 actions ordinaires «le $100 chacune et en 100 uctions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Ste-Foy, «listrict judiciaire «le Québec.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14725-o 995-66 Northland Shopping Centres (Canada) Limited Les Centres d'achats du Nord (Canada) limitée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, l'administrateur «lu gouvernement «le la province a accordé «les lettres patentes, en date «lu Se jour «le mars 1901).(constituant en corporation: Joseph E.Cassar.avocat, 1750.rue Prospect, Sherbrooke, Rita Breton, secrétaire, célibataire, 1027, rue Pacifique, Sherbrooke, et Yvette Drouin, secrétaire, épouse de Hervé Desjardins, 410, rue Florence, Sherbrooke, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie d'immeuble! et de construction, sous le nom de « Northland Shopping Centres (Canada) Limited Les Centres d'achats du Nord (Canada) limitée», avec un capital total de $100,000, divisé en 4,000 actions ortlinaires «l'une valeur au pair de $10 chacune et 600 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 158, rue Frontenac, suite 22, Sherbrooke, district judiciaire «le St-Fran«,-ois.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Doivillk.14725 5701-65 O.T.J.Ste-Rosalie Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé «les lettres patentes, en «late «lu 4e jour de mars 1966.constituant en corporation sans capital-actions: Laval Lapierre, mécanicien, Eugène Gossolin, boulanger, et Denis Girard, aide-arpenteur, tous trois de Ste-Rosalie, comté de Bagot.pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom «le «O.T.J.Ste-Rosalie ».Le montant auquel est limitée la valeur «les biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $15,000.Le siège social de la corporation est à Ste-Rosalie, comté de Bagot.district judiciaire «le St-Hyacinthe.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14725-c 851-66 E.Normand inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Paul I^anglais, traveller and representative, Jeannine Caron, housewife, wife separate as t«> properly of the said Paul Langlais, both of 2923 «le Courcelles, Ste-Foy.and Emilien Martel, chartered accountant, 17 «le la Savoie, Courville, for the following pur.poses : To carry on business dealing in all kinds of articles ami merchaiulise generally sold in a grocery store, umler the name of \"E.Normand inc.\", with a total capital stock of 820,000, divided into 100 common sliares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office «>f the company is at Ste-Foy.judicial district of Quebec.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 995-1 Hi Northland Shopping Centres (Canada) Limited Les Centres d achats du Nord (Canada) limitée* Notice is given that umler Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 8th day of March.190(5, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Joseph K.Cassar, lawyer, 1755 Prospect Street, Sherbrooke, Rita Breton, secretary, spinster.1027 Pacifique Street, Sherbrooke, and Yvette Droi-in, secretary, wife of Hervé Desjanlins, 410 Florence Street.Sherbrooke, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, umler the name of \"Northland Shopping Centres (Canada) Limited -Les Centres «l'achats «lu Nord (Canadai limitée\", with a total capital stock of $100.000.divided into 4,000 common shares of the par value of $10 each and 000 preferred shares of the pai value of $100 each.The head office of the company is at 15s Frontenac Street, Suite 22.Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.14725-o 5701-65 O.T.J.Ste-Rosalie Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 4th day of March, 1966.have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Laval Lapierre.mechanic, Eugène (iosselin.baker, ami Denis Girar«l, surveyor helper, all three of Ste-Rosalie, county of Bagot.for the following purposes: The organization of a recreation centre, under the name of \"O.T.J.Ste-Rosalie\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire or hold is to be limited, is $15,000.The head office of the corporation is at Ste-Rosalie, county of Bagot.judicial district of St-Hyacinthe.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 851-60 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 1966, Vol.OS, \\'o.16 2805 Oxford and Mansell Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur don gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date «lu He jour de mars 1066, «\u2022oust it liant en corporation: Gordon L.Kehen-bergi 4126, Bluerulge Crescent, C.Ralph Lipj>er.1350, ouest, Sherbrooke.Robert S.Litvack.5217, avenue Ponsard, tOUI trois de Montréal, «\u2022t Nathaniel IL Salomon, 11\"), chemin Dufferin.Hempstead, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Exercer un commerce de restaurateurs, BOUS le nom «le «Oxford ami Mansell Incorporated*, avec un capital total «le $40.000.«livisé en 20.000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées «le $1 chacune.(.e siège social «le la compagnie est 1.place Ville Marie, suite 3635, Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal, Le Sous-secrétaire île la province, Raymond Dorviu.k.1I72Ô 921-60 P.B.Properties Ltd.Avis est donné «m'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, l'administrateur «lu gouvernement «le la province a acconlé «les lettres patentes, en date du 48 jour «le mars 1960, constituant en corporation : Dimitrious Kourebes, chauffeur, Betty Brinia.travailleuse d'usine.t:pouse dudit Dimitrios Kourebes.tous tlcux «le 0116, rue Durocher, app.17, Outremont, et Popi Brinia.travailleur d'usine.7092.Chester.Montreal, pour les objets suivants: Exercer les affaires «l'une compagnie d'immeubles et «le construction, sous le nom «le « P.B.Properties Ltd, », avec un capital total de S 10.000, «livisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées «le $100 chacune.Ia' siège social de la compagnie est à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrftaire de la province, Raymond Douvillk.1 1725 938-66 P & H Specialties Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur dU gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de mars 1906, constituant en corporation: A lie Markoff, homme «l'affairés, 4902, avenue Melrose, Montréal, Maurice C.Laniel, avocat, 3405, avenue Belmore, Montréal, et Claude Joncas, avocat, 182, avenue «le l'Êpée, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs en plomberie, chauffage et réfrigération, sous le nom de « P & H Specialties Co.Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14725 994-66 Patsilk Investment Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur «lu gouvernement de la province a accordé des Oxford and Mansell Incorporated Notice is given that umler Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 8th «lay «>f March.1960, have been issued by the Administrator «)f the Government of the Province, Gordon L.Echenberg, 4125 Blueridge Crescent, C.Ralph Lipper, 4350 Sherbrooke West.Robert S.Litvack.5217 Ponsard Avenue, all three of Montreal, ami Nathaniel II.Salomon.95 Dufferin Road, Hempstead, all four advocates.f«)r the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, umler the name of \"Oxford and Mansell Incorporated'', with a total capital stock of $40.000.divided into 20,000 common shares of $1 each ami 20.000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 1 Place Ville Marie.Suite 3635.Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-.) 921-66 P.B.Properties Ltd.Notice is given that umler Part I of the Companies Act.letters patent, bearing «late the 4th day of March.1066, have l>een Issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Dimitrious Kourebes, chauffeur, Betty Brinia.factory worker, wife of the said Dimitrious Kourel>es.both of 0110 Durocher Street, Apt.17, Outremont, ami Popi Brinia, factory worker.7092 Chester.Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate ami «\u2022oustruction company, under the name t)f \"P.B.Properties Ltd.\", with a total capital stock of $10.000.divided into 1.000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district «>f Montreal.Raymon i) Dou villk.Assistant Secretary if the Province.14725-u 938-66 P & H Specialties Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Abe Markoff, business man, 4902 Melrose Avenue, Montreal, Maurice C.Laniel, a«lvocate, 3465 Belmore Avenue, Montreal, and Claude Joncas, advocate, 182 de l'Êpée, Avenue, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of plumbing, heating and refrigeration contractors, under the name of \"P & H Specialties Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 1,000 common sliares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-0 994-60 Patsilk Investment Club Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1906, have been issued by 230!) GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.23 avril 1966, 98' année, n° 18 lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1966, constituant en corporation: Louis H.Ilohrlick, avocat et conseil en Loi de la reine, 4300, avenue Western, Westmount, Stephen Goldschleger, avocat, .r)75S, avenue Glcnardon, Côte-St-Luc, Joan E.Stephens, 500, 40e Avenue, Lachine, Thérèse l'erreault, 10430, André-Johin, app.3, Montréal, et Ida Polisuk, 2070, rue Veniard, St-Laurcnt, ces trois dernières secrétaires, célibataires d'Age majeur, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de « Patsilk Investment Club Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 81 chacune et 38,000 actions privilégiées de 81 chacune.Le siège social de la compagnie est à.Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond I)ouv1li.v.14725 988-06 B.Patterson Garage Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de février 1966, constituant en corporation: Berwick Patterson, garagiste, Gwendolyn Patterson, ménagère, épouse commune en biens dudit Berwick Patterson, et Phoel>c Patterson, retraitée, veuve, tous trois de 16, avenue Laurelwood, Pointe-Claire, pour les objets suivants: Exercer le commerce de véhicules automobiles et faire affaires comme garagistes, sous le nom de « B.Patterson Garage Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 20, avenue Valois Bay, Pointe-Claire, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14725 38-06 the Administrator of the Government of tin Province, incorporating: Louis H.Rohrlick, advocate and Queen's Counsel, 4300 Western Avenue, Westmount, Stephen Goldschleger, advocate, 5758 Glenarden Avenue, Cote-St-Lue.loan E.Stephens, 500, 40th Avenue, Lachinc, Thérèse Perreault, 10430 André-Jobin, apt.3, Montreal, and Ida Polisuk, 2070 Veniard Street, St-Laurent, the latter three secretaries, spinsters of the legal age of majority, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Patsilk Invest ment Club Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of |] each and 38,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.RaYMON d I >OU villk, Assistant Secretary of the Province.14725-o 988-66 B.Patterson Garage Inc.Notice is given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, l>caring date the 1st day of February, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor porating: Berwick Patterson, garagist, Gwendolyn Patterson, housewife, wife common as to property of the said Berwick Patterson, and Phoebe Patterson, retired, widow, all three of 16 Laurelwood Avenue, Pointe-Claire, for the follow ing purposes: To deal in motor véhicules and to do business as garage-keepers, under the name of \"B.Patter son Garage Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 20 Valois Bay Avenue, Pointe-Claire, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-0 88-66 Les Placements Klcano inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de mars 1906, constituant, en corporation: Henri Fortin, notaire, 5120, 3e avenue est, Charlesbourg, Claude Royer, notaire, 2785, Poitiers, Ste-Foy, et André Cossette, notaire, 215, 75e rue est, Charlesbourg, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placement, sous le nom de « Les Placements KIrani> inc.», avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et en 450 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 509, boulevard Charest est, Québec, district judiciaire de Québec.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14725-0 1023-00 Les Placements Grande Allée inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement tie la province a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de mars 1906, constituant en corporation: Bruno Pateras, I^es Placements Elcano inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Henri Fortin, notary.5120, 3rd Ave.East, Charlesbourg, Claude Rover, notary, 2785 Poitiers, Ste-Foy, and André Cossette, notary, 215, 75th St.East, Charlesbourg, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Les Placements Elcano inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 common shares of $10 each and 450 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 509 Charest Blvd.East, Quebec, judicial district of Quebec.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 1023-00 Les Placements Grande Allée inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 9th day of March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Bruno Pateras, 11818 Frigon QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 1968, Vol.9H, Xo.18 2307 11818, rue Frigon, Montréal, Y van Macerola, 2805, me Marquette, Laval, et James Galileo, 1607, rue Massenet, Laval, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie d'immeubles et «le construction, sous le nom «le « Les Placements Grande Allée inc.», avec un capital total «le $40,000, «livisé en 4,000 actions ordinaires «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie est 10031.rue Laverdure, Mont n'ai, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.14725 1002-00 Polygraph Printing Inc.Avis est donné qu'en Vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé «les lettres patentes, en date du 17e jour de décembre 1965, constituant en corporation: Conrad Shatner, avocat, 4725.Pulton, Montréal, Rhode Cohen, secrétaire, célibataire, 143, Richelieu, St-Jean, «¦t Jo Ann Israel.3006.The Boulevard, Westmount.pour les objets suivants: Exercer le commerce d'imprimeurs généraux, sous le nom «le « Polygraph Printing Inc.», avec un capital total «le $40.000.divisé en 3.000 actions ordinaires de $10 chacune et 100 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie est 3737, boulevard Métropolitain, suite 1002, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.11725 5611-65 les Provisions de choix inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a acconlé des lettres patentes, en date du 9e jour de mars 1966, constituant en corporation: Richard Mclançon, commerçant, 3775, du Souvenir, Laval.Lilianne Kîrouac, commerçante, épouse séparée de biens de Gérard Kirouac, 8000.25e Avenue, St-Michel.et Gilles Chatel, avocat, 4530, Côte-des-Neiges, app.1015, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers-bouchers, sous le nom de « Les Provisions de choix inc.», avec un capital total de $40.000.divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.14725-0 973-06 Quebec Association of Teachers of Education Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie de la Loi «les compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a acconlé des lettres patentes, en date du 8e jour de mars 1960, constituant en corporation sans capital-actions: Raymond A.Cartwright, avocat, 71, chemin Devon, Baie d'Urfé, Ian G.W.Lundie, avocat.15, avenue Claude, Beaconsfield, et Donald Kujan, avocat, 3480, chemin Côte-«le-Liesse, -Mont Royal, pour les objets suivants: Représenter tous « professeurs d'école normale » dans les collèges de professeurs catholiques Street, Montreal, Yvan Macerola, 2805 Marquette Street, Laval, and James Galileo, 1007 Masse-net Street, Laval, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of u nul estate ami construction company, umler the name of \"Les Placements Grande Alice inc.\".with a total capital stock of $40,000.divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is ut 10031 Lavenlurc Street, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.14725-o 1002-66 Polygraph Printing Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 17th day of December, 1965.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Conrad Shatner, advocate, 4725 Fulton, Montreal, Rhoda Cohen, secretary, spinster, 143 Richelieu.St.Johns, and Jo Ann Israel, 3606 The Boulevard.Westmount.for the following purposes: To carry on the business of general printers, under the name of \"Polygraph Printing Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 100 prc-ferre«l shares of $100 each.The head office of the company is at 3737 Metropolitan Boulevard.Suite 1002, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-0 5611-65 L«\\s Provisions de choix inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of March, 1966, have been issued by the A«lministrator of the Government of the Province, incorporating: Richard Melançon, trader, 3775 du Souvenir, Laval, Lilianne Kirouac-, trader, wife separate as to property of Gérard Kirouac.8600, 25th Avenue, St-Michel, ami Gilles Chatel, lawyer, 4530 Côte-des-Neiges, apt.1615, Montreal, for the following purposes: To carry on business as grocers-butchers, umler the name of \"Les Provisions de choix inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head offi<>e of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.14725 973-06 Quebec Association of Teachers of Education Notice is given that under Part III of the Companies Act.letters patent, bearing date the 8th day of March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Raymond A.Cartwright, advocate, 71 Devon Road, Baie-d'Urfé, Ian G.W.Lundie, advocate, 45 Claude Avenue, Beaconsfield, and Donald Kujan, advocate.3480 Côte-de-Liesse Road, Mount Royal, for the following purposes: To represent all \"normal school professors\" in English Catholic Teachers Colleges, under the 2308 GAZETTE OFFICII AAA) DE QUÉBEC, 98 avril 1868, 98* année, n° 16 anglais, sous le nom de « Quebec Association of Teachers of Education ».Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière quo la corporation peut posséder est de 110,000.Le siège social de la corporation est 1015, côte du Heaver Hall, suite 405, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Soux-xecrétaire de la province, Raymond Douvillk.14725 5002-65 name of \"Quebec Association of Teachers of Education\".The amount to which the value of the immoveable property which may be owned or held by the corporation is to be limited, is 810,000.The bead office of the corporation is at 1015 Heaver Hill.Suite 405, Montreal, judicial (listrid of Montreal.Raymond Dot villi:.Axxixtant Secretary of the Province.14725-o 5002-65 Raphael 67 inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du Se jour de mars 1966, constituant en corporation: Pierre Mondor, avocat, Andrée Ruffo, ménagère, é|k>use séparée de biens dudit Pierre Mondor, tous deux de 1965, de l'Église, St-Laurent, Agathe Beau-champ, secrétaire, épOUse commune en biens de Robert Houde, 526, Marie-Thérèse, Ste-Thérèse, Wolfgang Langheit, restaurateur, et Huguette Ruffo, ménagère, épouse séparée de biens dudit Wolfgang Langheit, ces deux derniers de 5920, Panama, Brassard, pour les objets suivants: Organiser, acquérir, administrer et disposer de commerces d'hôtellerie, sous le nom de « Raphael 67 inc.», avec un capital total de §120,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 7455.boulevard Montréal-Toronto, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14725-o 641-66 Raphael 67 inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of March.1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Pierre Mondor.advocate, André Ruffo, housewife, wife separate as to property pf the said Pierre Mondor, both of 1665 de l'Eglise, St-Laurent, Agathe Beauchainp.secretary, wife common as to property of Robert Houde.526 Marie-Thérèse, Ste-Thérèse, Wolfgang Langheit, restaurateur, and Huguelte Ruffo, housewife, wife separate as to property of the said Wolfgang Langheit, the latter two of 5920 Panama, Brassard, for the following purposes: To organize, acquire, administer and alienate the hotel trade, under the name of \"Raphael 67 inc.\".with a total capital stock of §120,001!.divided into 200 common shares of 8100 each and 1.000 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 7455 Montreal-Toronto boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 041-till Maurice Rentner - Shedlack Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1906, constituant en corporation: Ben Schecter, avocat et conseil en Loi de la reine, Mervyn N.Rosenstein, avocat, Charles Spector, avocat, Raymonde Lutterman, secrétaire, célibataire, et Margaret McMartin, secrétaire, célibataire, tous les cinq de Montréal, pour les objets suivants: Confectionner des robes, costumes, manteaux et appareils vestimentaires jwur dames, en faire le commerce sous le nom de « Maurice Rentner \u2014 Shedlack Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1470, rue Peel, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymon d Docvillk.14725 915-00 Maurice Rentner - Shedlack Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th (lay of March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Ben Schecter, advocate and Queen's Counsel, Mervyn N.Rosenstein, advocate, Charles Spector, advocate, Raymonde Lutterman, secretary, spinster, and Margaret McMartin, secretary, spinster, all five of Montreal, for the following purposes! To manufacture and deal in dresses, suits, coats and women's apparel, under the name of \"Maurice Rentner \u2014 Shedlack Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of the par value of $1 each and 3,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at 1470 Peel Street, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-0 015-66 Restaurant Thomas inc.Thomas Restaurant Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de mars 1966, constituant en corporation: Alfred-B.Thomas, maître d'hôtel, Corrine Giguère, ménagère, épouse dudit Alfred-B.Thomas, tous deux de 2611, Restaurant Thomas inc.Thomas Restaurant Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Alfred-B.Thomas, matt re -d'hôtel, Corrine Giguère, housewife, wife of the said Alfred-B.Thomas, both of 2611 Place QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23.1066.Vol.ON.So.16 2309 Place Beauséjour, Ste-Foy, et John Thomas, gérant, 760, Chouinard, Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, traiteurs et aubergistes, sous le nom de « Restaurant Thomas inc.\u2014 Thomas Restaurant Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.1472ô-o 989.66 Restaurants - La Caravelle \u2022 inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de mars 1066, constituant en corporation: Jean Bruneau, 411, Quinn, Longueuil, Robert Dulude, 90, Galt, Dorion, tous deux avocats, Jeanne Lcsieur.10537, Bcrri, Montréal, Lise Désautels, 3484, 43e rue, St-Michel, et Lyse St-Louis, 611.Mercille.St-Laml>crt, ces trois dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à fournir de l'amusement au public et faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Restaurants « La Caravelle» inc.», avec un capital total de s 100,000.divisé en 8,000 actions classe « A » de 810 chacune et en 2,000 actions classe « B » de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est lOôO.iMHilevard des Laurentides, suite 350, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrêtaire de la province.Raymond Douvillk.l4725-o 043-00 S.M.R.Equipment Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du Se jour de mars 1000.constituant en corporation: Charles Wolf-son, avocat et conseil en Loi de la reine, Richard Boucher, agent d'immeubles, et Isabel Brodeur.secrétaire, célibataire, 611c majeure, tous trois de 1010, ouest, rue Ste-Catherine.Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'appareils de chauffage à air chaud et de climatisation, sous le nom de « S.M.R.Equipment Inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 2.000 actions ordinaires de $10 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 1400.rue St-Louis, St-Laurent.district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.14725 08546 Beauséjour, Ste-Foy, and John Thomas, manager, 700 Chouinard, Quebec, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, caterers and inn-keepers, under the name of \"Restaurant Thomas inc.\u2014Thomas Restaurant Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 100 common shares of a nominal value of 8100 each and 300 preferred shares of a nominal value of 8100 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Quebec.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.14725 080-66 Restaurants \"La Caravelle\" inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 7th day of March.1900, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Jean Bruneau, 411 Quinn.Longueuil, Robert Dulude, 00 Gait, Dorion.both advocates, Jeanne Lcsieur, 10537 Berri, Montreal.Lise Désautels, 34S4, 43rd St., St-Michel, and Lyse St-Louis.011 Mercille, St-Lambert, the three latter secretaries, spinsters of the full age of majority, for the following purposes: To carry on the business which consists in supplying the public with entertainment, and to act as restaurateurs, under the name of \"Restaurants \"La Caravelle\" inc.\", with a total capital stock of S100.000, divided into 8,000 class \"A\" shares of 810 each and 2.000 class \"B\" shares of 810 each.The head office of the company is at 1050 Laurentian Blvd., suite 350, Montreal, juidicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 043-66 S.M.R.Equipment Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 8th day of AI arch.1900.have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Charles Wolfson, advocate and Queen's Counsel.Richard Boucher, realtor, and Isabel Brodeur, secretary, spinster of the full age of majority, all three of 1010 St.Catherine Street West, Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in warm air heating systems and air conditioning systems, under the name of \"S.M.R.Equipment Inc.\".with a total capital stock of 840.000.divided into 2,000 (ommon shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 1400 St-Louis Street.St-Laurent.judicial district of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.14725-0 985-66 Le* Sacs à main Grand Prix inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies, l'administrateur du gouvernement «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1966, constituant en corporation: Bernard C.Forest, notaire, 3760, avenue Harvard, Montréal, Solange Julien, secrétaire, fille majeure.5306, Les Sacs à main Grand Prix inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March.1966.have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Bernard C.Forest, notary.3760 Harvard Avenue.Montreal, Solange Julien, secretary, fille majeure.5300 Bro- 2310 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 98 avril 1966, 98* année, n° 16 rue BrodbUF, Montréal, et Guy Lacoste, notaire, 3787, avenue Vendôme, Montréal, pour les objets suivants: Fabrication et commerce de bourses, sacoches, valises et autres produits similaires, sous le nom de « Les Sacs à main (îrand Prix inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions Ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 390 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 1800, rue Parthenais.Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de lu province.R av.m on l) Dou villk.l4725-o 714-00 Salon McGill Beauty Shoppe inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a acconlé des lettres patentes, en date du 7e jour de mars 1900.constituant en corporation: Norman ('.Denys.avocat, 110, Jasper, Mont-Royal.Jean-Roch Boivin.avocat, K960, rue St-l\"rbain, Montréal, et René Beaulac.avocat, 208, Molière.Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un ou des salons de beauté ou de coiffure, sous le nom de « Salon McGill Beauty Shoppe inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 466, rue Sherbrooke ouest.Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Soussecrétuirc de la province, Raymond Douvillk.14725-0 942-00 «leur Street, Montreal, and Guy Lacoste,notary, 37S7 Vendôme Avenue, Montreal, for the follow iug purposes: To manufacture and deal in purses, wallets, suit-cases and other similar products, under the name of \"Les Sacs à main Grand Prix inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 1.000 common shares of a nominal value <>t $1 each and into 300 preferred shares of a nomi nul value of $100 each.The head office of the company is at 1800 Parthenais Street, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.14725 714-6(1 Salon McGill Beauty Shoppe inc.Notice is given that umler Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 7th day of March, 1900, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Norman C.Denys, lawyer, 11(5 Jasper, Mont-Royal, Jean-Roch Boivin, lawyer, 8060 St-Urbain Street, Montreal, and René Beaulac, lawyer, 20S Molière, Montreal, for the following purposes: To operate one or several beauty or hair-dressing salons, under the name of \"Salon McGill Beauty Shoppe inc.\", with a total capital Stock of $40.000.divided into 400 common shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at 405 Sherbrooke Street West, Montreal, judicial nté, administrator, 9265 LaSalle Blvd., LaSalle, and Gérald Lafontaine, administrator, Estérel, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 1966, Vol.OS, No, 16 2311 Exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de « Simard Amin inc », avec un capital total de $100,000, divisé en 4,000 action! ordinaires de $10 chacune et en 6,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 11037, rue .lurry est, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire (le la province, Raymond Douvillk.l4725-o 000-66 Société Gesbec inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de janvier 1066, constituant en corporation: Denis Côté, comptable.7438, St-Dcnis.André Choquette, comptable, 631, Guizot est, et Roland Provost, comptable agréé, 1473, Joliette, tous trois de Montréal, lunules objets suivants: Faire affaires comme compagnie de financement, de placement et de portefeuille (holding), sous le nom de « Société Gesbec inc.», avec un capital total de $200,000, divisé en 50,000 actions ordinaires de $1 chacune, 250 actions privilégiées classe « A » de $100 cliacune et en 1,250 actions privilégiées classe « B » «le $100 chacune.I/C siège social «le la compagnie est à Mont-réal, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11725-0 28-05 Société Sèze inc.Avis est donné qu'en vertu «le lu première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province u accordé des lettres patentes, en «late du 3e j«>ur «le mars 1906, cons-lituunt en corporation: Armand Deniers, entrepreneur, 1200, 14e avenue, J.-Pierre Filion, entrepreneur, 043, 20e rue est, Arthur Simoneau, entrepreneur, 662, 15c rue sud, Jacques Foucault, employé de chemins de fer nationaux, 635, 9e avenue, Alphonse Goulet, marchand, 302, 23e rue, Jacques Lamontagne, marchand, 031, 10e rue, Dr Guy Grondin, médecin, 689, 9e avenue, Benoit Labrie, employé de l'Hydro-Québec, 1102, 9e avenue, Lionel Mitchell, gérant, 875, 21e rue, Ernest Moffet.gérant de Caisse Populaire, 941, 8e rue centre, Michel Momeau, rentier, 1035, 7e avenue centre, Armand Roberge, paysagiste, 1623, 7e avenue est, tous douze de Charny, J.-Itoch Bergeron, ingénieur, 1203, Argenteuil, Amlré Frechette, arpenteur-géomètre, 2655, Quatre-bourgeois, Roland Labrie, fonctionnaire, 832, avenue Rougemont, tous trois de Ste-Foy, et Marcel Carrier, entrepreneur, 19, Godbout, St-Romuald-d'Etchemin, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Société Sèze inc.», avec un capital total de $200,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 18,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est A Charny, district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.! 1725-0 882-66 Studio de Santé de Ste-Foy ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur To operate hotels, taverns, inns ami restaurants, under the name of \"Simard Amin inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 4,000 common shares of $10 each ami 0,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 3037 Jarry St.East, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 006-66 Société Gesbec inc.Notice is given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, l)caring «late the 4th day of January, I960, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Denis Côté, accountant, 7438 St-Denis, André ('hoquette, accountant.031 Guizot East, am! Roland Provost, chartered accountant, 1473 Joliette, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on a business as a finance, investment and holding company, under the name of \"Société Gesbec inc.\", with a total capital stock of 8200,000, divided into 50,000 common shares of 81 each, 250 preferred class \"A\" shares of $100 each and 1,250 preferretl class \"B\" shares of 8100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 28-65 Société Sèze inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 3e jour de mars 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Armand Demers, contractor, 1200, 14th Avenue, J.-Pierre Filion, contractor, 043, 20th Street, East, Arthur Simoneau, contractor, 662, 15th Street, South, Jacques Foupault, National Railways employee, 635, 9th Avenue.Alphonse Goulet, merchand, 302, 23rd Street, Jacques Lamontagne, merchant, 031, 10th Street, Dr.Guy Grondin, physician, GS9, 9th Avenue, Benoit Labrie, Hydro-Quebec employee, 1102, 9th Avenue, Lionel Mitchell, manager, 875, 21st Street, Ernest Moffet, Tratle Union Manager, 941, 8th Street Centre, Michel Morneau annuitant, 1035, 7th Avenue, Centre, Armand Rol>erge, landscaper, 1623, 7th Avenue, East, all twelve of Charny, J.-Roch Bergeron, engineer, 1203, Argenteuil, André Frechette, land-surveyor, 2655, Quatre-Bourgeois, Roland Labrie, civil employee, 832, Rougemont Avenue, all three of Ste-Foy and Marcel Carrier, contractor, 19, Godbout, St-Romuald-d'Etchemin, for the following purposes: To carry on business us u reul estute and construction company, under the name of \"Société Sèze inc.\", with a total capital stock of 8200,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 18,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Charny, judicial district of Quebec.Raymox d DOU vi 1.1.1-, Assistant Secretary of the Province.14725 882-00 Studio de Santé de Ste-Foy ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, Waring date the 2312 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril 1986, OS' année, n° 16 «lu gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de mars I960, constituant en corporation : Gérard ('hoquette, administrateur, Monique ('hoquette, ménagère, épouse séparée de biens dudit Gérard (\"hoquette, tous deux de 16, rue Highland, LaSalle, et Conrad ('hoquette, gérant, 763, l>oulcvard ('barest, Québec, pour les objets suivants: Exploiter, utiliser et diriger des studios de sauté, sous le nom de « Studio de Santé de Ste-Foy ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de 81 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chucunc.I>c siège social de lu compagnie est 969, route de l'Eglise, Ste-Foy, district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.14725 961-60 Syndcx inc.Avis est donné qu'en vertu de la première purtie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province u uccordé des lettres patentes, en date du 25e jour de janvier 1066, constituant en corporation: Mathieu Dubé, représentant.Cbristiane Beaumont, ménagère, épouse dudit Mathieu Dubé.tous deux de 5809, Jacinthes.Jean-Guy Vé/ina.poseur de tapis.3276, Place Tilleuls, tous trois d'Orsainville.Jules Cloutier, gérant, 3480.2e Avenue.Gaston Jean, étudiant.1405, de Longueuil, Jacques Lévesque, président.40.des Pins est.tous trois de Québec, Raymond Roberge.représentant S390.Place Montaigne, Jean-Claude Deshiens, professeur, 333.46e Rue.Paid Broehu, ingénieur professionnel, 014.70e Rue, tous trois de Charlesbourg.et Jean-Yves Plamondon, vendeur.87, Can»n.Lorcttevillc.pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placement, sous le nom de « Syndcx inc.».avec un capital total de 8200,000, divisé en 1.600 actions ordinaires de $25 chacune et en 6.400 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compagnie est 3480, 2e Avenue.Québec, district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douviixk.14725-o 326-66 7th day of March, 1900, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Gérard ('hoquette, executive, Monique Choquette, housewife, wife separate as to property of the said Gérard Choquette, ImMIi of 10 Highland Street, LaSalle, and Conrad Choquette, manager, 703 ('barest Boulevard, Quebec, for the following purposes! To operate, use and manage health studios, under the name of \"Studio de Santé de Ste-Foy ltée\", with u total cupitul stock of $40,000, divid-ed into 10,000 common ¦haresof $1 each and 3,0110 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 969 Route de l'Église, Ste-Foy, judicial «listrict of Quebec.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14726-0 061-66 Syndcx inc.Notice is given that under Purt I of the Companies Act, letters patent, bearing dute the 25th day (if January.1906.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Mathieu Dubé.representative.Cbristiane Beaumont, housewife, wife of the said Mathieu Dubé, both of 5869 Jacinthes, Jean-Guy Vé/ina.carpet layer.327(5 Place Tilleuls, all three of Orsainville.Jules Clout it r.manager.3480,2nd Avenue.Gust on Jean, student.1405 (le Longueuil, Jacques Levesque, president.40 des Pins East, all three of Quebec.Raymond Robergc.representative, 8800 Place Montaigne.Jean-( 'lande Desbiens, professor.333,46th Street.Paul Broehu.professional engineer, (514, 76th Street, all three of Charlesbourg, and Jcan-Vves Plamondon.salesman, 87 Caron.Lorcttevillc.for the following purposes: To curry on business us an investment company, under the name of \"Syndex inc.\".with a total cupitul stock of $200.000.divided into 1,600 common shares of $25 each and 6.400 preferred shares of $25 each.The head office of the company is at 3480, 2nd Ave.Quebec, judicial district of Quebec.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.14725 826-66 Taverne Concorde inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de mars 1966.constituant en corporation: Pierre Durand, avocat, 4027, Vendôme, Montréal, Michel Dagc-nais, avocat, 888, chemin Ste-Catherine, Gut remont, et Suzanne Boivin, secrétaire, fille majeure usant de ses droits.0460, Ernest-Lavigne, Alont-réal, pour les objets suivants: Exploiter une taverne, sous le nom de « Taverne Concorde inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 400 actions onlinuires de $100 chacune.Le siège sociul de lu compagnie est à Laval, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.14725-o 790-06 Theatre Technology of Quebec, Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première purtie de la Loi des compagnies, l'administra- Taverne Concorde inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dute the 7th day «f Match, 1966, have been issued h.v the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Pierre Durand, lawyer.4027 Vendôme, Montreal.Michel Dagenais.lawyer.383 Stc-Catherine Road, Gutremont.and Suzanne Boivin, secretary, fille majeure using her rights, (5460 Kmest-Lavigne, Montreal, for the following purposes: To operate a tavern, under the name of \"Taverne Concorde inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $10(1 each.The head office of the company is at Laval, judicial district of Montreal.Raymond Douvilli-:, Assistant Secretary of the Province.14725 700-66 Theatre Technology of Quebec, Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April S3, MU), Vol.9S, No.W 2313 leur «lu gouvernement de la province a accordé del lettres patentes, en «late «lu 10e jour «le mars 1906, constituant en corporation ! Wcin le II Un ward Laitlley, avocat et conseil en 1/oi de la reine, Anatole I,esyk.Harold Digby Clarke et Roger Stanley Ackinan.ces tr«>is derniers avocats, tous «piatrc «lu lie étage, 231 ouest, rue St-Jacquêt, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'étalage et d'acceMoirei d'éclairage à être utilisés mais non limités à des représentations théâtrales et artistiques, mc-iliums publicitaires, commerciaux et autres, sous le nom «le « Theatre Technology of Quebec, Ltd.».avec un capital total de $-10.000.«livisé «¦u 100 actions ordinaire! «le $100 chacune.I.C siège social «le la compagnie est à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.I.r Sous-sccrétuire de la province, Raymond DouVILLE.14725 1026-66 Thomas & Dilworth Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes, en «late «lu 28e jour «le février 1068, constituant en corporation: Cliffonl George Meek, comptable, 8101, avenue Maplewood, Montréal.Theodore William Martinson, commis, 4217.avenue Western.Westmount.et Colin Richard Chisholm.commis, 2534, boulevard Pie l\\.Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux «d de constructeurs, sous le nom «le « Thomas & Dibvorth Ltd., avec un capital total de $100,000, «livisé en S.000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $10 chacune et 2.000 actions privilégiées «rime valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond I)ouvi u.k.1172Ô S33-00 Vitrerie Harvey ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement «le la province a acconlé des lettres patentes, en date du 7e jour de mars 1000, constituant en corporation: J .-Vincent Fleury, avocat, 804.rue Dufour est, Aima, André Plour-de, comptable, St-Jérôme (Métabetchouan), et Yvette Gobeil, secrétaire, fille majeure, 80, rue Morin, Aima, pour les objets suivants: Faire le commerce du verre et «le tous les articles ou marchandises contenant du verre ou du silicium, sous le nom «le « Vitrerie Harvey ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Aima, district judiciaire de Roberval.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14725-o 710-60 La voix des parents de la régionale Louis-Hémon Avis est donne qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date «lu 8e jour de mars 1906, constituant en corporation sans capital-actions: Louiiefte Garneau, commerçante, épouse «le lOtII «lay of March, 1060, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Wendell Howard Laid-ley, advocate and Queen's Counsel.Anatole Lesyk, Harold Digby Clarke and Roger Stanley Ackman, the latter three advocates, all four Of llth Floor, 231 St.lames Street West, Montreal, f«>r the following purposes: To deal in displays ami lighting equipment t«> lie used in but not limited to theatre and art presentations, advertising media, commercial ami other media, umler the name of \"Theatre Technology of Quebec, Ltd.\", with a total capital stock «»f $10.000.divided into 100 common shares of $100 each.The head office «>f the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-0 1025-66 Thomas & Di I wort h Ltd.Notice is given that umler Part I of I he Companies Act.letters patent, bearing «late the 28th day of February.1900.have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province.incorporating: Cliffonl George Meek, accountant, 3101.Maplewood Avenue.Montreal.Theodore William Martinson, clerk, 1217 Western Avenue.Westmount, ami Colin Richard Chisholm.clerk.2534 Pie IX Boulevard, Montreal, for the following purposes: To carry on the business «>f general contractors and builders, umler the name «>f \"Thomas «x Dilworth Ltd.\", with a total capital stock of $100.000.divided into 8,000 common shares «>f the par value «>f 810 each ami 2.000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymon d Dou vi llk.Assistant Secretary of the Province.14725-0 833-00 Vitrerie Harvey ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of March, 1966, have l>een issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: J.-Vincent Fleury.advocate, 804 Dufour St.East, Alma, André I'lourde.accountant, St-Jérôme (Métabetchouan), and Yvette Gobeil, secretary, fille majeure, 80 Morin St., Alma, for the following purposes: To carry on business dealing in glass and in all articles or merchandise containing glass or silicon, under the name of \"Vitrerie Harvey ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Alma, judicial district of Roberval.Raymon d Douvillb, Assistant Secretary of the Province.14725 71946 La voix des parents de la régionale Louis-Hémon Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, hearing date the 8th day of March, 1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Louisette Garneau, merchant, wife of 2314 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, $$ avril 1900, 98' aimée, u° 16 Jew-Paul Tremblay, 122, rue des Cèdres, Xavier Dallairo, agent vendeur, 71, boulevard Walberg esl, tous deux de l)oll>cau, et Paul-Arthur Déry, commis voyageur, 4, rue Ste-.leun d'Are, St-Félicien, pour les objets suivants: Développer chez les parents le sens des respon-sabilités en matière «l'éducation, sous le nom de « La voix des parents de la régionale Louis-Hémon ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que |>eut acquérir et posséder la corporation, est de $75,000.Le siège social de la corporation est à Dolbeau, district judiciaire de Kolierval.Le Sous-secrétaire Je la province, Raymond Douvillk.I4725-0 431-00 Vulcan Inspection & Drafting Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, l'administrateur «lu gouvernement «le hi province a accordé «les lettres patentes, en «late du lie jour «le mars 1000, constituant en corporation: Samuel IL Shriar.Murray IL Spiegel et Ilarvey M.Cooper-Btone, tous trois avocats «le 1010 ouest, rue Ste-Catherine, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de dessin structural et «le projets en général, sous le nom «le « Yiih-an Inspection «x Drafting Ltd., avec un capital total de 140,000, divisé en 10,000 actions ordi- naircs «le $1 chacune et 30.000 actions privilégiées «le $1 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire dé la province.Raymond Douvillk.14725 1056-60 Ronald Williams Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date «lu 24e jour «le février 1900.constituant en corporation: Ronahl Williams, courtier «l'assurance, Dorothy Fitzgerald, ménagère, épouse séparée «le biens «bulit Roland Williams, et dûment autorisée par ce dernier aux fins «les présentes, tous deux «le 715.avenue Aea-«lia.Lacnine, et Henry Walker Williams, retraité.130.avenue Arlington.Westmount.|>our les objets suivants: Exercer un commerce «le courtiers et agents «l'assurance, sous le nom «le « Ronald Williams Inc.», avec un capital total «le $40,000.«livisé en 2.000 actions or«linaires «le $10 chacune et 2.000 actions privilégiées «le $10 chacune.Ix' siège social de la compagnie est à Mont- réal, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.14725 774-00 Jean-Paul Tremblay, 122 «les Cèdres Street, Xavier Dallaire, sales agent, 71 Walberg Houle vard Fast, both of Dolbeau, ami Paul-Arthur Déry, travelling salesman, 4 Ste-Jeanne d'Arc Street, St-Félicien, for the following purposes: To develop among parents the sense of responsibility in educational matters, under the name of \"La voix des parents de la régionale Lui is.Hémon\".The amount to which the value of the immoveable projierty which the corporation may acquire or hohl is to be limited, is $75,000.The hea«l office of the cor|x>ration is at I >olheau, judicial district of ltolierval.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 431-66 Vulcan Inspection & Drafting Ltd.Notice is given that umler Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date tlull th day of March.1066, have been issued hy the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Samuel II.Shriar.Murray 11.Spiegel and Harvey M.Cooperstone, all three advocates of 1010 St.Catherine Street West, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of structural designing ami drafting generally, umler the name of \"Vulcan Inspection & Drafting Ltd.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 10.000 common shares of $1 each ami 30.000 preferred shams of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douvii.i.k.Assistant Secretary of the Province.14725-0 1056-66 Ronald Williams Inc.Notice is given that umler Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of February, 1000.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Ronald Williams, insurance broker, Dorothy Fitzgerald, housewife, wife separate as to property of the said Ronald Williams, and duly authorized by him for the purpose of these presents, both of 715 Acadia Avenue.Lachine.and Henry Walker Williams, retired gentleman.130 Arlington Avenue, Westmount.for the following purposes : To carry on the business of insurance brokers ami agents, under the name of \"Ronald Williams Inc.\".with a total capital stock of $40,000.divided into 2.000 common shares of $10 each ami 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.14725-o 774-m» Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Alba Corporation Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en «late du 24e jour «le février 1900, à la compagnie « Alba Corpora-ration », 1° étendant ses pouvoirs; 2° augmen- Alba Corporation Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, hearing date the 24th day of February, 1066, babe l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of \"Alba Corporation\", 1.extending its powers; 2.increasing its capital from QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 2000, Pol.00, No.Hi 2315 tant son capital de 81,000 à 840,000, par la .'nation f 9.000 common shares of a par value of $1 each, 15,000 class \"A\" preferred shares «>f a par value t>f $1 each and 15,000 class \"B\" preferred shares of a par value of $1 each.Raymond Dorviu.k.Assistant Secretarif of the Province.14725-.» 3482-63 1313 23 Almar Imports Inc.Notice is given that, umler l'art I of the Companies Act.supplementary letters patent.hearing date the 20th day of December, 1905.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Almar Imports Inc.\".increasing its capital from $20.000 to $40,000.the additional capital stock being divided into 200 preferred shares «>f a par value of $100 each.Raymond Dorviu.k, Assistant Secretarif of the Province.14725-o 4781-64- 1312 0s Association provinciale des infirmiers du Québec Avis est donné qu'en vertu «le la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a acconlé, des lettres patentes supplémentaires en «late du 3e j«>ur «le mars 1000, à l'« Association provinciale «les infirmiers xboro-North Shore Library Association\", incorporated under the provisions of Part III of the said Companies Act, by letters patent f the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 11th day of March, 1900, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to \"J.A.Frenette inc.\", incorpo- 2310 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql'fiHEC, 23 avril 1966, 98' année, n° W inc.», constituée par lettres patentes en «late du 18e jour «le janvier 1968, changeant son nom en celui «le « Yvon Beyer inc.».Le Sous-secrétaire de lu province.Raymond Dot villi:.I472ô-o 151(86-62 1313/100 Marcel Bru lot te ltée Avis est donné «m'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes supplémentaires en date «lu 24e jour «le novembre 1965, à la compagnie « Mégantic Tire Service Inc.».constituée par lettres patentes en date «lu 16e jour «le novembre 1960, changeant son nom en celui «le « Marcel Brulotte ltck* ».Le Sous-secrêtaire de la province, RaYMOHD DoUVILLK.14725-0 14021-60 - 1313/54 Calendrier & botlin téléphonique du centre soeiul italien de l'Est inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes supplémentaires en date «lu 14e jour «le février 1066, à la compagnie « Calendrier & bottin téléphonique du centre social italien «le l'Est inc.», étendant ses pouvoirs.Le Sous-secré'tuirc de la province, Raymond Douvillk.14725-.» 3593-64 \u2014 1312 73 Casualaire inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies, l'administrateur «lu gouvernement de la province a accordé «les lettres patentes supplémentaires en date «lu lie jour de mars 1900, à la compagnie « Casualaire inc.», augmentant son capital «le 840,000 à 8100,000, le capital-actions additionnel étant «livisé en 0,000 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $10 chacune.Le Sous-secrêtaire de la province, R a y mon D DoU vi li.b.14725 13333-50 \u2014 1313,101 La Corporation des loisirs Si - André inc.Avis est donné qu'en vertu «le la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement «le la province a acconlé «les lettres patentes supplémentaires en «late du lie jour de mars 1900, à « La Corporation des loisirs St-André inc.», 1° augmentant le montant auquel sont limités les biens immobiliers que peut acquérir et posséder ladite corporation «le $10,000 à $200,000; 2° changeant le nombre «le ses a«lministrateurs «le 5 à 7.Le Sous-secrêtaire de la province.Raymond Douvillk.14726-0 5423-63 1313/35 Dopât Flooring Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnk'.s.le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé «les lettres patentes supplémentaires en date «lu 2e jour «le mars 1900, à la compagnie « Dopât Flooring Inc.», 1° augmentant son capital «le $10,000 à $00,000, le capital-actions additionnel étant «livisé en 500 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $100 chacune; 2° transportant son siège social de 0925, rue St-Dcnis.en la ville «le rated by letters patent «lated the Iftfch «lay <»f January, 1903, changing its name to that of \"Yvon Boyer inc.\".Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 15180-02 - \u2022 1313/Mm .Marcel Bru lotte ltée Notice is given that, under Part I «>f tin Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 24th «lay of Noveml>er, 1065, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Mégantic Tire Service Inc.\", incorporated by letters patent dated the 10th day of November, 19(H), changing its name to that of \"Marcel Brulotte ltée\".Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 14021-00 \u2014 1313 51 Calendrier & bottin téléphonique du centre social italien de l'Est inc.Notice is given that, umler Part I of the Companies Act.supplementary letters patent, hearing «late the 14th «lay of February, 1066, have l>ecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Calemlrier & bottin téléphonique «lu centre social italien «le l'Est in<\\\".extemling its powers.Raymond Douvillk, Assistant Secretarif of the Province.14725 3593-04 - 1312 73 Casualaire inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, hearing date the 11th day of March, 1900, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to \"Casualaire inc.\", increasing its capital from $40,000 to $100,000.the additional capital stock being divided into 0,000 preferred shares of a par value of $10 each.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.14725-u 13333-50 \u2014 1313/101 La Corporation des loisirs St-André inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 11th day of March, 1900.have been issued by the Administrator of the Government of the Province to \"La Corporation des loisirs St-André inc.\".1.increasing the amount to which the value of the immoveable propertv which the said corporation may own or acquire is $10,000 to $200,000 ; 2.changing the number of its directors from 5 to 7.Raymond Douvillk, Assistant Secretarif of the Province.14725 5423-03- 1313/35 Dopat Flooring Inc.Notice is given that, under Part I of the Comganies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 2nd «lay of March, 1900.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Dopat Flooring Inc.\".1.increasing its capital from $10,000 to 860,000, the additional capital stock being divided into 500 preferred shares of a par value of $100 each: 2.transferring its head office from 0925 St.Denis Street, in the city of Montreal, to 1900 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 1900, Vol.98, No.16 2317 .Montréal, à 1990, avenue Francis Hughes, en la cité de Laval, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrHaire de la province, Raymond Douvtlub.1172» 2708-63- 1312/77 Do/ids S|-Jcan limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé «les lettres patentes supplémentaires en date du 7«- jour de mars 1066, à la compagnie « Do/ois St-Jean limitée .1° augmentant le nombre «le ses administrateurs «le i à 5; 2° subdivisant ses .'ill actions ordinaires «léjà existantes «l'une valeur nominale «le $100 chacune en 5.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune; 3° augmentant son capital «le $5.000 à 846,000, le capital-actions additionnel «tant divisé eu 2,000 actions privilégiées catégorie « A » d'une valeur nominale de SU) chacune et en 2.000 actions privilégié «-s catégorie « H » «l'une valeur nominale de $10 chacune.I.r Sons-secrétaire de la province.Raymond Doivillk.14726-0 4075-47 1313/63 Drummond Ready iMix Ltd.Hélons Drummond ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur «lu gouvernement «le la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date «lu le jour f the Companies Act, supplementary letters patent! bearing date the 7th day of March, 1066, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to \"Dosois St-Jean limitée\", I.increasing the number of its directors from 4 to 5; 2.subdividing its 50 already existing shares of a nominal value of $100 each into 5,000 common shares of a nominal value of $1 each; 3.increasing its capital from $5.000 t«» $45,000.the additional capital shares being divided into 2.500 preferred category \"A\" shares of a nominal value of $10 each and into 2,000 preferred category \"It\" shares of a nominal value of 810 each.Raymond Dot vii.i.1 .Assistant Secretary of the Province.14725 4975-47 \u2014 1313/63 Drummond Ready Mix Ltd.Rétons Drummond ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act.supplementary letters patent, bearing «late the 4th «lay of March, 1066, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to \"Drummond Ready Mix Ltd.\".incorporated by letters patent dated the 27th day of April.1055.changing its name tt> that of \"Drummond Ready Mix Ltd.Bétons Drummond ltée\".Raymond Doi ville, Assistant Secretary of the Province.14725 11005-55 1312/132 Eastveld Industrial Realties Corp.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of March.1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province t«» \"Eastveld Industrial Realties C«»rp.\".expending its powers.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.14725-0 15847-60 1313/30 Équipements Universels Napierville inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act.supplementary letters patent, bearing «late the 7th «lay of March.1966, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to \"Equipements Universels Napierville inc.\".amending the provisions of its letters patent.Raymond Doivillk.Assistant Secretary of the Province.14725 550-04-1312/110 Gittleson Holdings Incorporated Notice is given tliat.under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, tearing «late the 9th «lay of March.1900, have l»een issued by the Administrator of the Government of the Province to \"Gittleson Holdings Incorporateil\", 1.reducing its capital from $408,740 to $451,740, the capital stock annulled 23 IS GAZETTE OFFICIELLE DE QEÈI1EC, §8 avril 190(1, 98' année, n° 10 étant divisé en 4,700 actions catégorie « B » «le $10 chacune; 2° modifiant les dispositions «le ses lettres patentes; 3° étendant ses pouvoirs, Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14725 10332-58\u2014 1313/41 being divided into 4,700 class \"H\" sliares of $10 each; 2.modifying the provisions of its letters patent; 3.extending its powers.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-0 10332-58- 1313/41 llogaii.McCuaig and Hood Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies, l'administrâleur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en «late «lu 7e jour «le mars 1900, à la compagnie « Northern Projects Limited », constituée en corporation par lettres patentes en date du 24e jour d'août 1950, changeant son nom en celui de « Hogan, .McCuaig and Hood Ltd.».Le Sous-secrétaire de la province, R aymqn d I )()u vi i.i.k.14725 12500-50\u2014 1312 '134 Hogan, McCuaig and Hood Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, tearing date tlie 7th day of March, 1000, have teen issued by the Administrator of the Government of the Province to \"Northern Projects Limited\", bieornorated by letters patent «laid the 24th day of August, 1950, changing its name to that of \"Hogan, McGuaig and Hood Ltd.\"'.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-0 12590-50 \u2014 1312 I :{| Irwin Dress Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé «les lettres patentes supplémentaires en date «lu 20e jour d'octobre 1905, à la compagnie « Irwin Dress Co.Ltd.», 1° modifiant les droits attachés aux actions -privilégiées; 2° redésignant ses 300 actions privilégiées existantes $100 chacune, comme «les actions privilégiées première catégorie; 3° augmentant son capital de $40,000 à $80,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 4,000 actions privilégiées, seconde catégorie «le $10 chacune; 4° subdivisant ses 100 actions ordinaires «le $100 chacune en 10,000 actions ordinaires «le $1 chacune; 5e convertissant ses 10,000 actions ordinaires de $1 chacune en 9,900 actions catégorie « A » «le $1 chacune et en 100 actions catégorie « B » de $1 chacune.Le Sous-secrêtaire de lu province, Raymond Douvillk.14725 13453-58 \u20141312/01 Irwin Dress Co.Ltd.Notice is given that, umler Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, tearing date the 20th «lay of October, 1065, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Irwin Dress Co.Lt«L\", I.modifying the rights attached to the preferred shares; 2.redesignating its 300 existing preferred shares of $100 each as first shares; 3.increasing its capital from $40,000 to $80,000, the additional capital stock teing divided into 4,000 second preferred shares of $10 each; 4.subdividing it-> 100 common sliares of $100 each into 10,01 in common shares of $1 each; 5.converting it> 10,000 common shares of $1 each into 9,000 class \"A\" shares of $1 each anil into 100 class \"R\" shares of $1 each.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-o 13453-58 \u2014 1312 61 Josbar Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Im'i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date «lu 7e jour «le février 1900.à la compagnie « Joshar Incorporated*, 1° augmentant son capital de $100.000 à $200,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 1,000 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $100 chacune 2° étendant ses pouvoirs.Le Sous-secrêtaire de la province.Raymond Douvillk.14725 7923-45 \u2014 1312/135 Joshar Incorporated Notice is given that, umler Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, tearing «late the 7th «lay of February.1900.have been Issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Joshar Incorporated\", I.increasing its capital from $100.000 to $200.000, the additional capital stock being divided into 1,000 preferred shares of a par value of $100 each; 2.extending its powers.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-o 7*923-45 \u20141312/135 La Laiterie She fiord limitée (Sheflford Dairy Limited) Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement «le la province a acconlé «les lettres patentes supplémentaires en date «lu 7e jour «le mars 1900, à la compagnie « La Laiterie Shcffonl limitée (Shefford Dairy Limited).» étendant ses pouvoirs.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14725-o 8022-40\u20141313 47 La Laiterie Shefford limitée (Shefford Dairy Limited) Notice is given that, umler Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, tearing «late the 7th day of March, 1900.have teen issued by the Administrator of the Government of the Province to \"La Laiterie Shefford limitée (Shcffonl Dairy Limited)\", extending its powers.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.14725 8022-46\u2014 1313 17 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 19m, Vol.98, No.W 2319 Landreville automobile* inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, le lieutenanl-goUVerneUf de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 14e jour de janvier 1900, à la compagnie « (tarage Dan.Lan-«Ireville inc.», constituée par lettres patentes en date du bSe jour «le novembre 1900.changeant son nom en celui de « Landreville automobiles inc.Le Soui-secrêtaire de lu province.Raymon d Douvillk.11725-0 14537-00- 1313/115 Rert .Mason & Son Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en «late «lu 7e jour «le mars 1066, à la compagnie « Quebec \\inusements Company Limited », constituée par lettres patentes en date «lu 15e jour «le décembre 1948, changeant son nom en celui de llerl Mason & Son Inc.»./.«\u2022 Sou.i-.tecr/taire de la province.Raymond Douvillk.i (725-0 7999-4S - 1312130 New Casa de la Pizza Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé «les lettres patentes supplémentaires eu «late du 1er jour de février 1966, à la compagnie « Puritana Restaurant Inc.?, constituée par lettres patentes en «late du 4c jour «le janvier 1966, changeant son nom en Celui «le « New Casa «le la Piz/.a In«\\ », Le Sous-secrêtaire de la province.Raymond Douvillk.14725 01-00 - 131314 Pascal Realties Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes supplémentaires en «late «lu 2e jour «le mars 1966, à la compagnie « Pascal Realties Limited », augmentant son capital «le $300.000 à $550.000, le capital-actions additionnel étant divisé en 25.000 actions privilégiées «le $10 chacune.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.11725 0200-48\u2014 1312 S0 Penny-Lou Corporation Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies, le licutcnant-gouverneur de la province a acconlé des lettres patentes supplémentaires en date du 2e jour «le mars 1900, à la compagnie « Penny-Lou Corpora lion», augmentant son capital de $40,000 à 880,600, le capital-actions additionnel étant «livisé en 4,000 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $10 chacune.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14725 572-00\u2014 1312/91 Placements La Vigueur inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a acconlé Landreville automobiles inc.Notice is given that, umler Part I of the Companies Act.supplementary letters patent, bearing «late the 14th day of January, 1906, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Garage Dan.Landreville inc.\", incorporated by letters patent «lated the 18th day of November.I960, changing its name to that of \"Landreville automobiles inc.\".Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.14725 14537-60\u2014 1313/115 Rert Mason & Son Inc.Notice is given that, umler Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 7th «lay of March, 1900, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to \"Quebec Amusements Company Limited\", incorporated by letters patent dated the 15th day of December, li'48, changing its name to that «>f \"Rert Mason & Son Inc.\".Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.14725 7999-48\u20141812/139 New Casa de la Pizza Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act.supplementary letters patent, bearing «late the 1st «lay of February.I960, have been Issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Puritana Restaurant Inc.\", incorporated by letters patent «lated the 4th day of January.1000).changing its name to that of \"New Casa de la Pizza Inc.\".Raymono Douville, Assistant Secretary of the Province.14725-0 01-00 \u2014 1313 14 Pascal Realties Limited Notice is given that, umler Part I of the Companies Act.supplementary letters patent, bearing «late the 2nd day of March.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Pascal Realties Limited\", increasing its capital from $300.000 to 8550,000, the additional capital stock being divided into 25.000 preferred shares of $10 each.Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.14725-o 0200-48 \u20141312'SO Penny-Lou Corporation Notice is given that, umler Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 2n«l day of March, 1900.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Pennv-Lou Corporation\", increasing its capital from $40,(KK) to $80.000, the additional capital stock being divided into 4.000 preferred shares of a par value of $10 each.Raymond Dot villi:.Assistant Secretary of the Province.14725-0 572-00 1312,91 Placements La Vigueur inc.Notice is given that, umler Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 9th day of March, 1900, have 2320 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 26 avril 100(1, OS' année, n° 10 «les lettres patente! supplémentaires en «late «lu 9e jour de mars 1966* à la compagnie « Placements La Vigueur inc.», convertissant ses 9,000 actions non «muses «le $10 cliacune en 9,000 actions privilégiées classe « A » «l'une valeur nominale «le $10 cliacune.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Doivillk.14726-0 400-66\u2014 1313/84 Quebec Hearing Aid Centre Inc.Centre auditif du Québec inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies, l'administrateur «lu gouvernement de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en «late «lu 4e jour «le mars 1900, à la compagnie « C.James Ward Limited », constituée par lettres patentes en «late du 28e jour «l'août 1904.changeant son nom en celui «le « Quebec Hearing Ai«l Centre Inc.Centre auditif «lu Québec inc.».Le Sou.*-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.1472Ô 3648-64 1313/16 been issued l>y the Administrator of the Government of the Province to \"Placements La Vigueur inc.\", converting its 9.000 unissued shares of $10 each into 9,000 preferred class \"A\" share* of a nominal value of $10 each.Raymond Douvillk.Issistant Secretary of the Province.1472Ô * 400-00 1313/84 Quebec Hearing Aid Centre Inc.Centre auditif du Québec inc.Notice is given that, under Part 1 of the Companies Act.supplementary letters paient, hearing «late the 1th «lay of March, 1000.have been issued by the Administrator of the Govern, ment of the Province t«> \"('.James Ward Limited\", incorporated by letters patent dated the 28th «lay of August.1904, changing its name In that of \"Quebec Hearing Aid Centre Inc.(\"en-tre auditif «lu Québec inc.\".Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.1472,r)-o 3648-64 1313/16 Raymond-Stephen Mortgag<-& Investment Corp.Avis est donne qu'en vertu de la première pari ie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes supplémentaires en date «lu 20e jour de novembre 1905, à la compagnie « Raymond-Stephen Mortgage & Investment Corp.», 1° augmentant son capital «le $11,000 à $111,000.le capital-actions additionnel étant divisé en 10.000 actions privilégiées catégorie « B » d'une valeur au pair «le $10 chacune; 2° changeant ses 10,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune, en 10.000 actions privilégiées catégorie « R » d'une valeur au pair «le $1 cliacune./.c Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14725 11012-59 \u2014 1312 117 Raymond-Stephen Mortgage & Investment Corp.Notice is given that, under Part I of tbe Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 20th earing «late the 1st «lay of March, 1900), have been issued by the Lieutenant-Governor of t lu-Province to \"Rocheleau automobile ltée\", 1.subdividing its 1,000 common shares of $100 each into 19,000 class \"A\" shares of $5 each and into 1,000 class \"R\" sliares of $5 each; 2.reducing its capital from $350,000 to $230,880, the annulled capital shares being divided into 1,312 preferred shares of $10 each ami into 10,000 preferred shares of $10 each; 3.increasing its capital from $230,880 to $000,000, the additional capital shares being divided into 30,312 preferred shares of $10 each.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 3000-40 \u2014 1313 17 Ste.Rose Land Sales Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, hearing date the 4th day of March, 1900, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to \"Ste.Rose Land Sales Inc.\", increasing its capital from $10,000 to $110,000, the additional capital stock being QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, April iff, /.%«, Vol.98, So.16 riant divisé en 100,000 actions privilégiées «l'une valeur au pair de SI chacune Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.14726 12955-50 \u2014 1313/91 Scenic Realty Corp.Avi> est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies, l'administrateur du gouvernement «le la province a accordé des lettres patentes supplénu-ntaires en «late «lu 7e jour «le mars 1900.à la «\u2022ompagnie « industrial Scientific Instruments Ltd.constituée par lettres patentes en date du 16e jour de juin 1054.I°«'hangennt son nom en celui «le « Scenic Realty Corp.; 2° étendant ses pouvoirs, 3° réduisant le nombre de ses administrateurs de 5 à 3; 4° convertissant ses 5.000 actions ordinaires non émises d'une valeur au pair «le SI cluicune en 5.000 \u2022 niions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.I.c Sou.s-sccrétairc de la prorince.Raymond Douvillk.I 1725 11441-54\u2014 1313/87 Simkovits Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partit- «h- la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes supplémentaires en «late «lu 1er jour de mars 1900, à la compagnie « Simkovits Holdings Ltd.1° convertissant ses 23.442 actions privilégiées émises d'une valeur BU pair de 11 chacune et ses 26,558 actions privilégiées non einiscs d'une valeur au pair «le SI chacune en 23,442 actions privilégiées catégorie * A émises d'une valeur au pair de SI chacune et en 26,558 actions privilégiées catégorie « A non émises d'Une valeur au pair «le SI chacune; 2.convertissant ses 140.058 actions privilégiées émises d'une valeur au pair «le SI chacune et ses 159.342 actions privilégiées non émises «l'une valeur au pair «le Si chacune en 140.058 actions privilégiées catég«>ric « B «l'une valeur au pair «le SI chacune et en 150.342 actions privilégiées catégorie « Il \u2022 non émises «l'une valeur au pair «le SI chacune; 3.modulant les droits attachés aux ait ions privilégiées.Le Sous-secrêtaire de la province.Raymond Douvillk.I 1725 14899-01 - 1312-05 Starto-Jct inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la I.t>i «les compagnies, le licutcnant- gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes supplémentaires en «late du 1er jour «le mars 1900.à la compagnie * Starto-.let inc.augmentant son capital «le $50.000 à $150.000.le capital-actions additionnel étant divisé en 350 actions ordinaires «le $100 chacune et en 650 actions privilégiées «le $100 chacune.Le Sous-secrêtaire de la province.Raymond Dot villi:.1172ô>o 1021-05\u2014 1312/03 Super-Marché Raymond liée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement «le la province a accordé «les lettres patentes supplémentaires en «late «lu 3e jour de mars 1900, à la compagnie « Super-Marché Raymond ltt'e », augmentant son capital divided into 100,000 preferre«l shares of a par value of $1 each.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725-0 12955-50) \u2014 1313/91 Scenic Realty Corp.Notice is given that, umler l'art 1 of the Companies Act, supplementary letters patent, hearing «late th«- 7th «lay of March.1900.have been issued by the Administrator of the Government of the Province to \"Industrial Scientific Instruments Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 16th «lay of June, 1954.l.changing its name to that of \"Scenic Realty Corp.\"; 2.extending its powers; 3.reducing the number of its directors from 5 to 3; 4.converting its 5.000 unissued common shares «>f a par value of 81 each into 5.000 preferred shares of a par value of 81 each.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.14725-o 11441-54 - 1313 87 Simkovits Holdings Ltd.Notice is given that, umler Part 1 of the Companies A«-t.supplementary letters patent.bearing date the 1st «lay of March.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Simkovits Holdings Ltd.\", 1.converting its 23.442 issued preferred shares of a par value of 81 each ami its 20.558 unissued preferred shares «>f a par value of SI each into 23.442 issued class \"A\" preferred shares of a par value «)f 81 each and into 26,558 unissued class \"A\" preferred shares of a par value of 81 each; 2.converting its 140,058 issued preferred shares of a par value of 81 each and its 159,342 unissued preferred shares of a par value «)f SI each into 140.058 issued class \"R\" preferred shares of a par value of $1 each and into 159.342 unissued class \"B\" preferred shares of a par value of $l each; 3.modifying the rights attached to the preferred shares.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.14726-0 14899-61 - 1312 05 Starto-Jet inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, hearing date the 1st «lay of March.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Starto-.let inc.\".increasing its capital stock from $50.000 to $150.000.the additional share capital being divided into 350 common shares of $100 each ami 050 preferred sliares of $100 each.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 \" 1621-05\u2014 1312 93 Super-Marché Raymond ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, hearing date the 3rd day of March, 1960, have been Issued by the Administrator of the Government of the Province to \"Super-Marché Raymond ltée\".increasing its capital stock from $40.000. 2322 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, >à avril 1000, US' année, n° W de $40,000 à $100,000, le capital-actions a.hli- tionncl étant divisé en 6,000 actions privilégiées de $10 cliacune.Le Sous-secrêtaire Je la province, Raymond Doi vii.i.j:.14725-o 14612-60 1312/95 Telecommunications de l'Est limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du Se jour de mars 1006, à la compagnie « Télécommunications des Iles-dc-Ja-Madeleinc limitée », constituée par lettres patentes en date du 15e jour de septembre 1960.1° changeant son nom en celui de « Télécommunications de l'Est limitée »; 2° augmentant son capital de $1,(K)0,000 à $5,000,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 400,000 actions ordinaires «le $10 chacune.Le Souê-êeerêtaire Je la province, Raymond DOUVILLE.14725-0 13659-60- 1313; 52 to $100,000, the additional share capital being divided into 6,000 preferred shares of $10 each, Raymond Doi; villi-:.Assistant Secretary of the Province.14725 14012-00 1312/98 Télécommunications de l'Est limiter Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the Nth day of March, 1900.have been issued by the Administrator of the Government of the Province t«» \"Télécommunications des Ues-dc-la-Madeleine limitée\", incorporated by letters patent «lated September 16, 1001».1.changing its name to that of \"Télécommunications «le l'Est limitée\"; 2.increasing its capital stock from $1.000.000 t«> $5,000,000, the additional share capital being divided into 400,000 common shares <>f $10 each.Raymond Doivili.'.Assistant Secretary of the Province.14725 13659-60\u20141313/52 Arrêtés en Conseil Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 451 Québec, le 22 mars 1966.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la Régie «les rentes «lu Québec.Ix* ministre «les finances recommande: que soit approuvé.sous l'autorité «le l'article 227 «lu Régime «le rentes du Québec (13-14 Elizabeth IL chapitre 24).dans sa version française et anglaise, le règlement adopté par la Régie des rentes du Québec à sa séance du 15 mars 1900 et dont copte est annexée à la présente proposition.( 'opie conforme.Le Greffier du Conseil Exécutif, Jacques Pbemont.RÉGIfl des RENTES do QUEBEC Règlement adopté sous l'autorité du Régime de rentes du Québec (13-14 Eliz.II.ch.24).Titre* I Définitions et applications 1.01.Pour les fins «lu Régime de rentes du Québec et «lu présent règlement, les expressions suivantes signifient : a) «organisme international': un organisme dont fait partie le Canada soit qu'il s'agisse d'une institution reliée à l'organisation des Nations-Unies en vertu de l'article 03 de sa sa charte, soit qu'il s'agisse d'une institution formée dans le but «le maintenir la paix internationale ou le bien-être social et économique «l'une communauté «le nations: 1.02.Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient : «) « loi » : le Régime de rentes du Québec: 1.03.Travail au service de Sa Majesté du chef du Canada: Le travail dans la province au service Orders in Council Order in Council Executive Council Chamber Number 451 Québec, March 22, 1966.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the Quebec Pension Board.The Minister of Finance recommemls: That under the authority of section 227 of the Quebec Pension Plan (13-14 Elizal>eth II, chapter 24), the English ami French versions of the Regulation, copy of which is attached hereto, adopted by the Québec Pension Hoard at its sitting held on March 15, 1966, Iw approved.Certified copy.Jacques Premont, Clerk of the Executive Council.Quebec Pension Board Regulation made umler the Quebec Pension Plan (13-14 Eliz.II, C.24) Title I Definitions and Application 1.01.For the purposes of the Quebec Pension Plan and this Regulation, the following expressions mean : (a) \"international organization\": an organization of which Canada is a member, whet lui such organization is brought into relationship with the United Nations in accordance with Article 03 of the Cliarter of the Ignited Nations, or whether such organization has as its primary purpose the maintenance of international peace or the economic or social Well-being of a community of nations: 1.02 In this Regulation, the following expressions mean: (a) \"Act\": the Quebec Pension Plan.1.03.Employment by Her Majesty in right of Canada: Employment in the Province by Her QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 1999, Vol.OS, No.18 2323 lie Sa Majesté du chef du Canada, ou au service d'un mandataire «le Sa Majesté du chef du Canada, est considéré comme un travail visé.('««pendant le travail comme membre «les forces canadiennes ou «le la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que le travail «pli donne droit à une pension en vertu de la Ix>i sur les jugée demeure un travail exclu.1.04.Administrateur résidant hors du Canada: be travail d'un particulier qui ne réside pas au ( auada et qui acquiert la qualité «le salarié en vertu de la loi uniquement par suite «le la charge qu'il exerce comme administrateur d'une corporation est un travail exclu, si cette charge est exercée totalement ou partiellement hors du ( 'auada.1.05.Travail au service d'un employeur résiliant hors de la province: Le travail dans la province au service «l'un employeur qui n'a pas d'établissement «lans la province, est un travail exclu.Toutefois, ce travail devient un travail visé si l'employeur conclut, pour ses salariés qui resident au Canada et qui reçoivent leur rémunération d'un établissement «le l'employeur situé hors du Canada, un arrangement avec la H(:gic quant au paiement de contribution! à l'égard ¦ h- ce travail.1.00.Dans le ca>« de l'article LOS, le salarié qui travaille pour un employeur qui n'a pas d'établissement dans la province est censé exécuter son travail dans la province.a) si le salarié y travaille ordinairement ou y effectue oitUnnirèment la plus grande partie de son travail, ou /») si le salarié y réside, «lans tous les cas «>ù on ne peut le déterminer selon le paragraphe a).1.07.be paragraphe b) «le l'article 53 «le la loi ne s'applique pas à l'égard «lu travail «l'un particulier qui est considère comme travail visé en vertu «lu deuxième alinéa de l'article 1.05.L.08.Tiavail hors du Canada: Le travail exécuté hors du Canada, qui serait visé s'il était exécuté «lans la province, est considéré comme travail visé s'il est exécuté pour le compte d'un employeur qui possède un établissement dans la province et si l'employeur conclut, pour ses salariés qui résidaient dans la province au moment de leur engagement, un arrangement avec la Itégic «piant au paiement «le contributions à l'égard de ce travail.Cet article ne s'applique pas au travail dans une entreprise de transport au sens de la section I de ce règlement.1.09.Travail d'un fonctionnaire hors de la province: Le travail d'un citoyen canadien, hors rie la province, à titre d'agent général, fonctionnaire ou préposé de la province, est un travail visé.Skctiox I Entreprises de transport 2.01.Dans la présente section, les expressions suivantes signifient: a) « travail «lans une entreprise de transport » : le travail d'un salarié au cours d'une période de paie dans une entreprise de transport par route, par air, par rail ou par eau, lorsque ce t ravail constitue le travail auquel s'adonne principalement ce salarié dans la |>ériode de paie et «pie ce travail s'exécute partiellement dans la province et partiellement hors du Canada; Majesty iu right of Canada, or by an agent of Her Majesty in right of Canada, is included iu pensionable employment un«lcr the Act.Employment, however, as a member of the Canadian Forces or the Royal Canadian Mounted Police, or employment conferring the right to a pension under the Judges Act remains excepted employment.1.04.Directors Resident Outside Canada: The employment of an individual who is not ordinarily resident in Canada, ami who is an employee within the meaning of the Act by virtue only of his |>osition as a corporation director, is excepted employment if such employment is perfor-med wholly or partly outside of Canada.1.05.Employment by an Employer Resident Outside the Province: Employment in the Province by an employer having no establishment in the Province is excepte»! employment.Such employment, however, shall l>c pensionable employment if the employer, in respect of employment performed in the Province by his employees resilient in Canada, and whose remuneration is pai«l from an establishment of the employer situated outside Canada, makes an arrangement with the Hoard for the payment of contributions in respect of such employment.1.00.For the purposes of section 1.05, the employee of an employer having no establishment in the Province shall t>e deemed to Ik* employed in the Province: (a) if the employee ordinarily works therein or ordinarily does the most work therein; or (b) in any case where a determination cannot he made under paragraph (a), if the employee resides therein.1.07.Paragraph (b) of section 53 of the Act does not apply in respect of the employment of an individual that is included in pensionable emplovment by the second paragraph of section 1.05.1.08.Employment outside Canada: Employment outside of Canada, that would be pensionable employment if it were in the Province, shall be included in pensionable employment if performed for an employer having an establishment in the Province ami if the employer, in respect of his employees \\vh«> were engaged at a time they were resident in the Province, makes an arrangement with the Hoard for the payment of contributions in respect of such employment.This section does not apply to employment in a trans|H>rtation enterprise as defined in Division I of this Regulation.1.00.Employment of an Officer or Servant of the Province Outside the Province: Employment outside the Province of a Canadian citizen as an agent-general, officer or servant of the Province is pensionable employment under the Act.Division I Transportation Enterprises 2.01.In this Division, the following expressions mean : (a) \"employment in a transportation enterprise\": the employment of an employee in a pay period in a transportation enterprise by road, by air.by rail or by water, where such employment is the employment primarily engaged in by that employee in the pay period ami is performed partly within the Province and partly without Canada; 2324 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril Î986, 98* aimée, i,° la b) « période de paie *\\ une période de paie tel que définie dans le Règlement concernant les contributions au Régime «le rentes «lu Québec (Arrêté en conseil numéro 2494 «lu 23 décembre 1965).2.02.Aux fins «le la présent»' section, une gare, une cour «le t riage, un aérogare, un quai, un entre- p6t, un garage OU Une remise est censé un établissement «h- I employeur.Nonobstant les dispositions de la présente section, le travail «lans une entreprise «!«\u2022 transport n'est pas considéré Comme travail visé, à moins «pie ce soit un travail qui serait visé s'il «tait exécuté entièrement dans la province.Le travail dans une entreprise «le transport qui n'est pas un travail visé par la présente section est un travail exclu.2.04.Transport par route: Le travail dans une entreprise de transport par route, considéré»' aux fins présente habituellement au travail à un établissement «le son employeur situé dans la province.2.06.Le travail dans une entreprise «h- transport par route, considérée pour les fins «le la Loi de l'impôt sur I»' revenu comme uneentreprise «les Etats-Unis d'Amérique, est un travail exclu.Toutefois, dans le cas du salarié qui réside au Canada «d se présente habituellement au travail à un établissement «le son employeur situé dans la province, la partie «le ce travail qui est exécuté au Canada peut être considérée comme «lu travail visé si l'employeur »'«>n<'lut l'arrangement mentionné à l'article 1.05.2.00.'Transport par air: Le travail dans une entreprise «le transport par air.considérée comme un transporteur international par air et un transporteur national par air par le Règlement sur tes services aériens commerciaux adopté le 0 août 1965 sous l'autorité de la Loi «lsiir l'aéronautique, est un travail visé lorsque le salarié se présente habituellement au travail à un établissement «le son employeur situé dans la province.2.07.'Transport par rail: Est considérée comme travail visé, dans le cas «lu travail dans une entreprise de transport par rail, dont la principale place «l'affairés est située au Canada, cette partie du travail «pie l'employeur détermine, selon les normes approuvées par la Régie, être exécutée au Canada, si le salarié se présente habituellement au travail «lans la province.2.0S.Est considérée comme travail visé, dans le Cas «lu travail «lans une entreprise «le transport par rail, dont la principale place d'affaires est située hors «lu Canada, cette partie du travail que l'employeur détermine, selon les normes approuvées par la Régie, être exécutée au Canada, si le salarié réside au Canada et se présente habituellement au travail «lans la province.2.00.Transport par eau: Le travail «lans une entreprise de transport par eau est un travail visé si le salarié réside dans la province et exécute ce travail en vertu d'un contrat (l'engagement «le l'équipe conclu au Canada en vertu «le la Loi sur la marine marchande «lu Canada.14752-») (h) \"pay period\": a pay period 08 defined iu the regulation respecting contribution t«) the Quebec Pension Plan (Order in Council number 2404 of December 23.1966).2.02.Per the purposes of the present division, a station, marshalling yard, airport, pier, wharl.warehouse, garage or workshop shall be deemed to be an establishment of the employer.2.03.Notwithstanding the provisions of this division, employment in a transportation enter prise is not pensionable employment unless it is employment that would he pensionable employ ment if it were wholly within the Province.Employment in a transportation enterprisi Which is not pensionable employment umler this division is excepted employment.2.04.Transportation by road: Employment in a transportation enterprise by road that i« regarded, for the purposes «>f taxation umler the Income Tax Act.as an enterprise of ( 'auada.shall be pensionable employment if the employee is resident in Canada and ordinarily report* f»»r work at an establishment of his employei situated in the Province.2.05.Employment in a transportation enterprise by road that is regarded, for the purposes of taxation under the Income Tax Act.as an Enterprise of the United Slates of America is excepted employ ment.If.however, the employee is resident in Canada and ordinarily reports for work at an establishment of his employer situated in the Province, that part of such employment performed in Canada shall b«- Included in pensionable employment if the employer makes the arrange nient mentioned iu section 1.05.2.00.Transportation In/ air: Employment in a transportation enterprise by air.classified as an international air carrier and as a domestic air carrier umler the Commercial Air Service Regulations, adopted the Oth of August 1905 under the Aeronautics Act.shall be pensionable employment if the employee ordinarily reports for work at an establishment of the employer situated in the Province.2.07.Transportation by rail: Pensionable employment includes, in tin- case of employ ment in a transportation enterprise by rail, whose principal place of business is in Canada, that part of the employment determined by tlie employer (under standards approved by the Board) to be in respect «>f employment in Canada, if the employee onlinarily reports for work in the Province.2.0S.Pensionable employment includes, in the case of employment in a transportation enterprise by rail, whose principal place of business i> outside of Canada, that part of the employment determined by the employer (umler standards approved by the Board) to be in respect of employment in Canada, if the employee is resident in Canada and ordinarily reports for work in the Province.2.09.Transportation In/ uater: Employment in a transportation enterprise by water is pensionable employment if the employee is resident in the Province ami performs such employment umler an agreement with the crew entered into in Canada umler the Canada Shipping Act.14752-0 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April M./.%'«.Vol.Us, So.n; 2:i2o Arrêté en coneeil < ham lue du Conseil Fxécutil' Numéro 587 Québec, le 2î) murs i <\u2022*>«>.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le classement d'objects mobiliers et artistiques appartenant à la Fabrique de la paroisse «le St-r'ian«,ois.Ile d'Orléans.ii.B8T ordonné, sur la proposition du Ministre «les Affaires culturelles: Que soit approuvé le classement comme objets mobiliers et artistiques, fait par résolution rné de perlons laits au puiiieon; burettes en laiton argenté; encensoir en laiton, formes trapues (1764); /<) Peintures: L'Immaculée Conception, copie faite par A.Plamondon (1854); L'éducation de la Vierge.<'opi<- faite par A.Plamondon (1854); portrait «!«\u2022 l'abbé Leclerc, copie faite par A.Plamondon (1884); Saint-François de Sales, «le F.lia il huge (179N): e) Sculptures: liane «l'oeuvre, commencé par L.-X.Leprohon et terminé par L.-T.Berlinquet 1840-44); bénitier dont la vasque est en pierre de llcauport et le pieds en bois sculpté, peint en longe vin: 8 lustres en fil «le fer et bois dont les noeuds sont godronnés; chandelier pascal en bois sculpté et doré, peut-être Noël Levassent- (1773); madone en lois sculpté; 4 anges en bois sculpté, non signé mais proviennent de l'ancien maître-autel sculpté par les Levasseur en 1771-73: 0 grands chandeliers «l'autel en bois sculpté, Simon Nadeau.probablement; 2 crucifix en bois; croix de procession en bois mouluré, aucune signature, serait l'oeuvre «l'André Pacpiet; chaire.(1842) L.-X.Leprohon; fonts baptismaux, Olivier Sain-son (ISÔ4).Que le présent décret s«>it publié «lans la '\"Ztle ifficielle de Québec «-t ait force de Ix>i à compter «le la «late «le sa publication.( tapie conforme.Le Grejfier du Conseil Exécutif, 14778-0 Jacques Prêmont.Order in Council Executive Council Chamber Number f>('>7 Québec, March 29, 1966.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the classification «>f moveable and artistic objects belonging to the Fabrique «le la paroisse de St-François, Island of Orleans.It is ordered, upon the recommendation of the Minister «>f Cultural Affairs: That the classification as moveable and art ist i«' objects, made by resolution of the Quebec Historic Monuments Commission, on February 28, 1 000, with the consent of the proprietor, of the following moveable objects, Ik- approved, to wit : (a) Silverware: Solid silver Chalice, by Laurent Amyot (1806); solid silver Salvar used in wedding ceremonies for the rings of the couple, VR RIKA probably an achievement of PftUi Lambert dit Saint Paul: solid silver .Monstrance, by L.Amyot (1800); box for Holy Oil.in silver, by L.Amyot (1708); a tray for Alter-ereuls, iu silver, by L.Amyot (1798); solid silver Censer, by L.Amyot (1807) book «>f accounts; solid silver Incense-box, by L.Amyot, (1807); 2 solid silver Altar-cruets, by L.Amyot, (1831, book of accounts); solid silver Ciborium.I M probably by J.-B.Meusnier.Ciborium, small silver Ciborium whose e«>v<'r l>cars Acanthus leaves, JC LF; solid silver pyx made in the shape of a watch, unmarked, (1718) bo«>k of accounts; Shrine «>f Saint François de Sales, Swiss School «>f the XVII century; a case of solid silvi*r, containing two containers of the same metal, by G.L.Guillaume Loir; solid silver Chalice, by F.R.François Ranvoyzé (177)1); instrument «le paix, by François Ranvoyzé; 2 solid silver Altar-cruets, by François Ranvoyxé; a yellow leather Ineense-ls)x ornated with beads made by a puncheon; silvered brass Altar-cruets; a brass Censer, compact form (1704); (b) Paintings: The Immaculate Conception, copy made by A.Plamondon (1854); The Education of the Virgin, copy made by A.Plamomlon ( 1854); Portrait of Father Leclerc, copy made by A.Plamondon (1884); Saint François de Sales, by F.Baillargé (1798); (c) Sculpture: Churchwardens' pew.started by L.-X.Leprohon and finished by L.-T.Berlin-guel (1840-44): Holy-water basin, the basin being made of Beauport stone and the foot wood carved; painted wine rod; 8 chandeliers in iron wire and Wood having Hutted knots; Paschal candlestick wood carved ami in gold, probably by Noël Levasseur (1773): a wo«)«l carved Madonna; 4 wood carved angels, unsigned but coining from the former high altar carved by the Lcvasseurs in 1771-73; 0 great alter caml- lesticks, wood carved* Simon Nadeau, probably, 2 wooden crucifixes; Proeessitm cross in moulded woo«l, no signature, should be the work «)l* André Paquet, pulpit.(1842) L.-X.Leprohon; baptismal fonts, Olivier Samson (1854); That the present decree Ik- published in the Quebec Official Gazette ami have force t>f law from ami after the «late of its publication.True copy.Jacques Prêmont, 14773 < lerlc of the Executive Council. 2326 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 99 avril 1996, OS' année, n° 16 Arrêté en conseil Chambre «lu Conseil Exécutif Order in Council Executive Council Chamber Nuraéro 571 Québec, le 29 murs 1966.Présent: be Lieutenant-gouverneur en conseil.concernant un amendement à l'article 48 «les Règlements relatifs à la protection des salariés travaillant sur les chantiers «le construction et dans les tranchées (arrêté en conseil nos 662 du 27 juin 195(1, 121LF «lu 3 décembre 195S.1834 «lu 15 septembre 1965, 1930 du 29 septembre 1905 et 310 du 23 février 1900).Il est ordonné, sur la proposition oratoires «le la Canadian Standards Association ont vérifié que leur fabrication est conforme aux normes établies par CSA Z04.1 et le Ministère du Travail «lu Québec.L'arrêté en conseil no 310.du 23 février 1900 est abrogé.» Copie conforme.Le Greffier du Conseil Exécutif, 14736*0 Jacques Prémont.Number 571 Québec, March 29, lOOti.Present: The Lieutenant-Governor in Council, concerning an amendment to section 4.S of tile Regulations respecting the protection of employees working in construction yards anil in trenches (Onlers in Council numbers 052 of .bine 27, 1050; 1211 (F) of December 3, 1958; 1834 of September 15, 1905; 1930 of September 29, 1905 ami 310 of February 23, 1900).It is ordained, Upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour: That a thin! paragraph, as quoted below, he added to section 48 of the Regulations respecting the protection of employees working in construction yards and in trenches: \"As to June 1, 1900, all safety helmets sold in Québec shall bear a label certifying that the Canadian Standards Association's laboratories have verified that their manufacture comply with the standards set by CSA Z94.1 and the Quéliec Department of Labour.Order in Council number 310 of February 23, 1000 is rcsciiuled.\" True copy.Jacques Prémont, 14736-0 ( lerk of the Executive Council.Assemblée Meeting La compagnie du chemin de fer Alma & Jonquières Les actionnaires «le « La compagnie «lu chemin de fer Aima & Jonquières » sont convoqués en en assemblée générale annuelle le mardi, vingt-six avril 1000, à trois heures «le l'après-midi, au numéro 1, «le l'immeuble place Ville-Marie, à Montréal, pour recevoir les comptes «le l'exercice 1905.procéder à l'élection «les administrateurs et à la nomination «les vérificateurs pour le prochain terme d'office et pour délibérer sur toute autre question «lu ressort «le l'assemblée.Le Secrétaire, 14027-15-2-o J.R.TuROEON.The Aima & Jonquières Railway Company The annual meeting of the shareholders of \"The Alma & Jonquières Railway Company\", to receive the 1905 financial statements of the company, to elect directors and appoint auditors for the ensuing year, and to transact such other business as may properly come before the meeting will be held in the 31st floorboard room, 1, Place Ville-Marie, Montreal, on Tuesday, April 26, 1900, at three o'clock in the afternoon.14627-15-2-0 3.R.Turgeon, Secretary.Associations coopératives Cooperative Associations Association coopérative de l'école secondaire Le Iter (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le secrétaire de la province a approuvé la formation «le l'association coopéra-tive « Association coopérative de l'école secondaire Le Rer ».Le siège social de cette association coopérative est situé à Sherbrooke, Québec, dans le district électoral «le Sherbrooke.Quélx'c, le 15 avril 1900.Le Sous-secrétaire de la province, 14781-o Raymond Douvillk.Association coopérative de l'école secondaire Le Ber (Cooperative Associations Act) Notice is hereby given that the Provincial Secretary 1ms approved the formation of the cooperative association \"Association coopérative de l'école secondaire Le Ber\".The head office of this cooperative association is situated in Sherbrooke, Quebec, in the electoral district of Sherbrooke.Quebec, April 15, I960.Raymond Douvillk, 14781 Assistant Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April $$, M6, Vol.88, No.w 2327 Association coopérative de travail de Riviere Davy (Loi den associations coojtératives) Avis est donné que le secrétaire de la province a approuvé la demande «lu syndicat coopératif « Syndicat de travail «le Rivière Davy » «le cesser d'être régi par la Ix>i des syndicats ctxipé-ratifs «le Quél>ec, et de «levenir une association régie par la Loi «les associations «coopératives, sous le nom «le « Association coopérative «le travail de Rivière Davy ».Québec, le 15 avril 1900.Le Sous-secrétairc de la province, 14782-0 Raymond douville.Association coopérative d'habitat ion de Maniwaki (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le secrétaire «le la province a approuvé la f«>rmation de l'association coopérative « Association coopérative «l'habitation de Maniwaki », Le siège social de cette association coopérative est situé à Maniwaki, QuébeCj «lans le «listrict «'\u2022leetoral «le (iatineau.Québec, le 15 avril 1966, Le Sous-secrétaire de la province, 14783-0 Raymond Douville.Association coopérative du collège Mont-St-Lotiis ( Loi des associations coopérât ires) Avis est «lonné que le secrétaire de la province a.approuvé la formation de l'association coopérative « Association coopérative du c«)llègc Mont-St-Louis ».Le siège social «le cette association coopérative est situé 244 est, rue Sherbrooke.Montréal, Québec, dans le district électoral de St-.ïac«|ues.Québec, le 15 avril 1900.Le Sous-secrétairc de la prorince, I47S4-0 Raymond Douville.V-socialion coopérative du corps étudiant du collège St-Paul (Loi des associations coopérât ires) Avis est donné «pie le secrétaire de la province a.approuvé la formation «le l'association coopérative « Association otx>pi:rative du corps étudiant «lu collège St-Paul ».Le siège social «le cette association coopérâtive est situé au Collège St-Paul.10,555.Bois-de-Boulogne, dans le «listrict électoral de Laval.Québec.Québec, le 15 avril 19(10.Le Sous-secrétairc de la prorince, 14786-0 Raymond douville.L'Association coopérative forestière de l'Ascension de Patapédia (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le secrétaire de la province a, approuvé la formation «le l'association cf the cooperative syndicate \"Syndicat «le travail «le Rivière Davy\", that it cease being governed by the Queliec CoojH'rative Syndu-ates Act, ami become an association governe«l by the Cooperative Associations Act, under tin- name of \"Association cooperative de travail «le Rivière Daw\".Quebec, April 15.1966.Raymond Douvillk, 147S2 Assistant Secretary of the Province.Association «'oopérative «l'habitat ion d«' Maniwaki (Cooperative Associations Act) Notice is hereby given that the Provincial Secretary has approved the formation of the cooperative association \"Association coopérative d'habitation «le Maniwaki\".The head office of this cooperative association is situated at Maniwaki, Quebec, in the electoral district of (iatineau.Quebec, April 15, 1000.Raymond douville, 14783 Assistant Secretary of the Province.Association coopérative «lu collège Mont-St-Louis (Cooperative Associations Act) Notice is hereby given that the Provincial Secretary has approved the formation of Uncooperative association \"Association coopérative «lu collège Mont-St-Louis\".The head office of this cooperative association is situated at 244 Sherbrooke St.East.Montreal.Quebec, in the electoral district of St-Jacques.Quebec.April 15.1900.Raymond Dot vii.i.k.14784 Assistaid Secretary of the Province.Association coopérative «lu corps étudiant du collège St-Paul (Cooperative Associations Act) Notice is hereby given that the Provincial Secretary has approved the formation of the cooperative association \"Association coopérative «lu corps étudiant «lu collège St-Paul\".The head office of this cooperative association is situated in Collège St-Paul.10.555 Rois-dc-Roulogne.in the electoral «listrict of Laval.Quebec.Quebec.April 15.1900.Raymond Doivillk.147S5 Assistaid Secretary of the Province.L*Association coopérative forestière de l'Ascension de Patapédia [Cooperative Associations Act) Notice is hereby given that the Provincial Secretary has approved the formation of the cooperative association \"L'Association coopérative forestière «le l'Ascension de Patapédia\".The head office of this cooperative association is situated at l'Ascension «le Patapédia, Quebec, in the electoral district of Hanaventure.Québec, April 15.1900.Raymond Doi vii.i.k.14780 Assistant Secretary of thr Province. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 99 avril 1969, 98* année, n° 16 2328 Association coopérative télévision «h- Percé {Lui îles associations coopérât ires) Avis est donné que l«i secrétaire de lu province a.approuvé hi demande «lu syndicat coopératif « Cooperative télévision de Percé \u2022 «le cesser d'être régi par la Loi des syndicats coopératifs de Québec, et «le devenir nue association régie par la Loi des associations coopératives, sous le nom de « Association coopérative télévision de Percé .Québec, l«- 15 avril 1966./.c Sons-secrétaire de la province.14787-0 Raymond Doi vii.i.k.Avis Marie-Yvonne Aboussafy Prenez avis que Mlle Marie-Yvonne Alxmssafy, demeurant et domiciliée au numéro 5 Redpath Place, à Montréal, district de Montréal, s'adressera sous peu par voie de requête au Secrétariat de la Province «lans le but de lui demander que son nom devienne « Henriette Rolland ».Montréal, le 7 avril 1966.Les Procureurs de la requérante, Prévost, Trudeau & Bibaillon.14068-15-2-0 Ville de St-Hubert Avis public est par les présentes donné que la « Ville de St-Hubert », présentera au Lieutenant-Gouverneur en Conseil une requête aux fins d'obtenir l'émission «le lettres patentes pour remplacer par les paragraphes 11°, ll°a et 11 °6, de l'article 427 «le la Loi «les Cités et Villes l'article 23 de sa charte (6-7 Elizabeth II, chapitre 112) concernant principalement l'enlèvement et la destruction des vidanges, le paiement du coût de ce service soit par une taxe soit par une comixmsation.Le Secrétaire-trésorier, 14669-15-2-0 L.Gérard Leclkuc.Claudia Romana Heldmaier Avis est par les présentes donné que Claudia Romana Heldmaier, mieux connue sous le nom de Claudia Romana Mueller, étudiante, domiciliée actuellement au numéro 66 de la rue Lafo-rest, à Repentigny, dans le district de Montréal, province de Quebec, a transmis au Secrétaire de la Province, une requête demandant que son nom soit changé de Claudia Romana Heldmaier à « Claudia Romana Mueller ».Aucune personne ne sera affectif par ce changement de nom.Montréal, le 7 avril 1966.Le Procureur de la requérante, 14684-15-2-o Paul Massé.kaz Leopold Jakim Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil par le décret numéro 628, du 5 avril 1966, d'effectuer le changement «le nom «le Kazimierz Leopold JakimcEuk en celui de « Kaz Leopold Jakim ».Québec, le 15 avril 1966.Le Sous-secrétaire de la province, l4725-o Raymond Doivillk.Association <*oopcrutivc télévision «le Percé {Cooperative Associations Act) Notice is hereby given that the Provincial Secretary has approved the request of the cooperative syndicate \"Cooperative télévision de Percé\" that it cease being governed by the Cooperative Syndicates Act, and become an association governed by the Cooperative Associations Act.under the name of \"Association coopérative télévision de Percé\".Quebec, April 15.10*10.Raymond Doi villi;.14787 Assistant Secretary of the Province.Notices Marie-Y von ne Aboussafy Takc notice that Miss Marie-Yvonne Aboussafy, living at 5 Redpath Place, Montreal, district of Montreal, will ask the Provincial Secretary by way of petition to cliange her name to \"Henriette Rolland\".Montreal, April 7, 1966.PhKVOST, TliUDKAU & RlSAILLON, Attorneys for petitioner.14668-16-2-0 Town of St-Hubert Public notice is hereby given that the \"Town of St.-Hubert\", will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council for the issue of letters patent to replace by paragraphs 11°, ll°«z and 11°/;, of section 427 of the Cities ami Towns Act section 23 of its charter (6-7 Elizabeth II, chapter 112) concerning particularly the collection ami destruction of garbage, the payment for such service either by a tax or by a compensation.L.gérard Leclkrc, 14669-15-2-o Secretary- Treasurer.Claudia Romana Heldmaier Notice is hereby given that Claudia Romana Heldmaier, l>etter known under the name of Claudia Romana Mueller, student, residing at 66 Laforest Street, Repentigny, in the «listrict of Montreal, province of Quebec, has transmitte«l to the Provincial Secretary, a petition requesting the change of her name from Claudia Romana Heldmaier to \"Claudia Romana Mueller.\" This change of name will affect no person.Montreal, April 7, 1966.Paul Massk, 14684- 15-2-o Attorney for petitioner.Kaz Leopold Jakim The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 628, dated April 5, 1966, to effect the change of name of Kazimierz Leopold Jakimczuk to that of \"Kaz Leopold Jakim\".Quebec, April 15, 1966.Raymond Douvillk, 14725 Assistant Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, Mid, Vol.US, No, 16 Léo Sediey Il u plu au lieutenant-gouverneur ou conseil, par le ddcret numéro G2ô, du ô avril 196*6, d'effectuer le changement «le nom de Léo Bed-le/ky en celui de « Léo Sedlev ».Québec, le lô avril 1966.Le Sous-secrêtaire de la province, 14726-0 Raymond Doi-villk.Keué \\ alitionl Il a plu au lieutenant-gouverneur on conseil, par le décret numéro 62G, du 5 avril 190(5, d'effectuer le changement «le nom de René Veinberg en celui «le « René Valmont », Québec, le lô avril 1000.Le Sous-secrêtaire de la province, 14726-0 Raymond Douvillk.Robert Michael W in row Il a plu au lieuleiianl-gouverneiir on conseil, par le décret numéro 027, «lu ô avril 1000, d'effectuer le changement de nom de Robert Michael Weinrauch en celui de « Robert Michael Win row ».Québec, le lô avril 1000.Le Sous-secrêtaire de la province, 14726-0 Raymond Douvillk.Perry Klenk Avis est donné «pie « Raymond Desroehers .vendeur, «le 3859, boulevard LaSalle, Montréal, m'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un ordre changeant le nom «le son fils Perry Klenk à Perry Desrochers de la même adresse.Daté à Montréal, 13 avril 1006.i 1702-10-2 John M.SciiLESiNGBR, Ch.Thomas Zcmclmaii Avis est donné «pie Thomas Zemelman, dessinateur industriel, résidant à 6311, avenue Somerle«l.appartement 200.«lans la ville «le Montréal, s'adressera au Lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un ordre changeant son nom eu celui de « Thomas Zimmerman: ledit changement de nom bénéficiera aussi a son épouse, née Katia Weglissewski, «le la même adresse.Montréal, 11 avril 1000./.«¦.v Procureurs de Thomas Zenulniait.Chait, Aronovitch, Ki.kin.Salomon, 14763-16-2 GBLBER & BrONHTEIN.J.U.Dubé Ltée Avis est donné au public, conformément à l'article 8 de la I^oi «In régime «les Faux ( 'ourantes.que la Cie J.B.Dubé Ltée de Lac des Iles, «lans le comté «le Lahellc, se propose de demander l'autorisation «le faire un barrage à la décharge du bac dos Iles sur le lot lô.rang ô.Avis est «le plus donné qu'une requête à cotte lin, accompagnée «les plan et devis indiquant remplacement choisi pour la construction de ces ouvrages et le terrain (ou les terrains, selon le CSS,) qui seront affectés par le refoulement «les eaux, a été transmise au ministre dos Richesses Naturelles, et qu'un duplicata «le ces plan et devis a été déposé au bureau «le la division d'enregistrement de babello.à M«ml-I.aurier.La demande contenue «lans la requête sera prise en considération le OU après le jour suivant 2329 Léo Sedlev The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by «lecroe number 625, dated April ô.1000, to oil'ect the change of name «>f Léo Sed-le/.ky to that of \"Léo Sediey\".Quebec, April lô, 1966.Raymond Doi villi;, 14726 Assistunt Secretary of the Province.René Vulmoiit The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by «lecroe number 020, dated April ô, 1000, to effect the change of name of René Veinberg to that of \"Rone Valmont\".Quebec, April lô.1000.Raymond Douvillk, 14725 .tssistant Secretary of the I'roriiice.Robert Michael Winrou The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by «lecree number 027, dated April ô, 1000, to effect the change of name of Robert Michael Weinrauch to that of \"Robert Michael Winrow\".Quebec, April lô, 1900.Raymond Doivillk, 1472Ô Assistant Secretary of the Province.Perry klenk Notice is given that \"Raymond Desroehers\".salesman, of 3859 LaSalle Blvd., Montreal, will apply t«> the Lieutenant-Governor in Council for an order changing the name of his son Perry Klenk to Pony Desroehers of the same address.Dated at Montreal.April 13, 1006.14762-16-2-0 John M.Schlesinger, q.c.Thomas Zemelman Notice is hereby given that Thomas Zeinchnau.Industrial Draftsman, residing at 6311 So-merled Avenue, Apartment 200.in the city of Montreal, will apply tt> the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to \"Thomas Zimmerman\"; said change of name shall also benefit his wife, born Katia Weglis- zewski of the same address.Montreal.April 11.1966.Ciiait.Aronovitch, Ki.kin.Salomon, Gelber & Hkonstiin.14703-10-2-o Attorneys for Thomas Zemelman.J.R.Dubé Ltd.Public notice is hereby given in accordance with section 8 of the Watercourse Act that Cie j.lb Dubé Ltd.of Lac «les [les, in the county «>f Labelle, intends to apply for authorisation to construct a dam at the discharge of Lac des Iles on lot lô, range ô.Notice is also given that a petition tt> that effect, accompanied by a plan and specifications of such work, showing the site chosen for the construction thereof and the land (or lands, as the case may be) which will be affected by the hacking up of the water, has been forwarded to the Minister of Natural Resources, ami that a duplicate of such plan and specifications has been deposited at the registry office of the registration division of Labelle, at Mont-Laurier.The application contained in the petition will he taken into consideration on or alter the «lay I___ 2330 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 08 avril 2000, 98* année, n° 16 la date de la dernière publication «lu présent avis dans la Gazette officielle du Québec.1.H.Dubé ltée.Le Président.i 1770-10-1-,.JeaN-Gi y .Ikxmncs.following the dute of I lie last publication of this notice in tin- Quebec Official Gazette.J.B.Dubé Ltd.11 : a x -( î V y Jl-'.xxixus, 14776-10*4 President.Sydney Hot ten berg Avis est donné que Sydney Hnttcuhcrg.vendeur, résidant à 5608.rue Pincdalc.(ôte-St-Lilc, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, afin d'obtenir un ordre lui permettant de changer son nom en Celui de « Sydney Ross .ce changement devra également servir à sa femme.Miriam Ross, à son fils.Ian Harris Rottenberg, et à sa fille Dcbra Fait h Ilotteiiherg.tous île la même adresse.Montréal.18 avril 1000.Lea Procureurs du requérant, Spiegel, Shuiau.14777-16-2 Polar & CoopBRirroNE.Sydney Rottenberg Notice il hereby given that Sydney Rottenberg, salesman, residing at 6608 Pinedale Street.Côbé-St-Luc, district of Montreal will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to \"Sydney Ross\": said change of name will also benefit his wife, Miriam Ross, his son, Ian Harris Rottenberg, ami his daughter.Debra Faith Rottenberg.all of the same address.Montreal.April IS.1000.Spiegel, Siiriar, polak & coopbrbtoxe, 14777-16-2-0 Attorneys far applicant.Municipalité de Sully Avis est donné par les soussignés que le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté en date du 5 avril 1966, un arrêté en conseil ayant pour objet de changer le nom de la municipalité de Saint-Dsvid-d Estcourt, comté de Fémiscouata, en «\u2022«\u2022- llti de « Municipalité de Sully .Conformément aux dispositions de l'article 48 du Code municipal, ce changement de nom entre en vigueur à compter de la publication du présent avis dans la Gazette officielle de uébec.Sully, Ht avril 1000.Le Maire, Lionel Charest.Le Sécréta in-trésorier, 1470Ô-o AlMÊ Roy.Municipality of Sully Notice is hereby given by the undersigned, that the Lieutenant-Governor in Council has, on April 5, 1000, adopted an Order in Council having for purpose to change the name of the municipality of Saint-David-d'Ksetcourt.county of Té-miscouata, to that of \"Municipality of Sully\".Pursuant to the provisions of section 4X of the Municipal Code, this change of name is in effect as from the publication of the present notice iu the Quebec Official Gazette.Sully.April 10.1000.Lionel Chares?, Mayor.Aimé Roy.14795 Secretary- Treasurer.Loi électorale de Québec Avis concernant une agence de publicité (art.377) .le donne avis, par les présentes, que l'agence île publicité « Maurice Waticr Publicité Ltée », 2055, rue Peel, Montréal, est reconnue comme mandataire de monsieur Jean Morin.agent officie] «lu Parti libéral «lu Québec pour la présente élection dont le scrutin est fixé au 5 juin 1901).Québec, 10 avril 1900.Le Président général des élections.14737-0 François Drouin, c.r.(Quebec Flection Act Notice concerning a publicity agency (sec.377) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Maurice YVatier Publicité Ltée\", 2055, Peel St., Montreal, is reeogni7.e«l as the authorized agent «)f Mr.Jean Morin, official agent of the Liberal Party of the Province of Quebec for the present election for which voting is fixc«l for June 5, 1966.Quebec, April 19.1966.François Drouin, y.t:.14737-») Chief Hctuming-Officer.Loi électorale de Québec Avis de nomination d'agents officiels (art.375) Je donne avis, par les présentes, «pie l'honorable Jean Lesage, ci»., C.B., Premier ministre et Chef «lu Parti libéral de la province «le Québec, a nommé, conformément aux dispositions de l'article 375 «le la Loi électorale, les trois personnes suivantes pour agir comme agents officiels dudit parti libéral «le la province de Québec au cours de l'élection «lont le scrutin est fixé au 5 juin 1966: M.Paul llédanl, homme «l'affairés, 940, Chemin St-Louis.Québec.M.Jean Morin.administrateur, 905, avenue Pratt.Outremont.Quebec Election Act Notice of appointment of officiel agents (section 375) I give notice, by these presents, that the Honourable Jean Lesage, p.c., Q.g., Premier and lea«ler of the Liberal Party of the Province of Quebec, has appointe»!, pursuant to the provisions of section 375 of the Election Act.the three following j)crsons to act as official agents of the said Liberal Party of the Province of Quebec during the ele«-tion for which voting is fixed for June 5.1966: Mr.Paul Bédanl, businessman, 940 St-Louis Roa«l.Quebec.Mr.Jean Morin, administrator.905 Pratt Ave., Outremont. QUEBEC OFF IC LIE GAZETTE, April 2d, i960, Vol.08, No.10 2331 M.T.H.Ryan, homme d'affaires.330, rue Simeoe, Ville Mont-Royal.Québec, le 19 avril 1901).he Président général des (lections, 14737-0 François Drouin, ch.Mr.T.R.Ryan, businessman.330 Simone St., Town of Mount Royal.Quebec, April 19.1900.Kkançois Drouin, q.c, 14737 < liief Returning-Officer.Loi éIcet<>rale de Quebec Avis de nomination d'agent officiel (art.876) .le donne avis, pur les présentes, (pie monsieur Daniel Johnson, cit.Chef du partie do lTiuon Nationale, a nommé-, conformément au\\ dispositions de l'article 375 de la Loi électorale, la personne suivante pour agir comme agent officiel dudit parti de l'Union Nationale au cours de l'élection dont le scrutin est fixé au ô juin 1000: M.Charles-Eugène Doucet, imprimeur.3241, Place Hélène Roulé.Montréal.Québec, le 19 avril 1900.Le Président général des élections.14737-0 François Drouin, ch.(laisses d'épargne et de crédit Quebec Meet ion Act Notice of appointment of official agent (section 873) I give notice, by these presents, that Mr.Daniel Johnson, Q.c.Leader of the Union National Party, has appointed, pursuant to the provisions of section 375 of the Election Act.the following person to act as oilicial agent of the said I'nion National Party during the election for which voting is fixed for June 5, 1000: Air.Charles-Eugène Doucet, Printer.3241, Hélène Roulé Square, Al ont real.Quebec, April 10.1966.François Drouin, q.c, 14737-0 Chief Returning-Officer, Savings and Credit Unions Cuisse d'Economie des travailleurs de Drummondville (Lot des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le secrétaire de la province a approuvé la formation de la caisse d'épargne et de crédit « Caisse d'Economie des travailleurs de Drummondville ».Le groupe dans lequel la caisse recruterai ses membres sera les employés dos compagnies St-l'rancis Teinture.Eagle Pencil et Eastern Paper box.Le siège social de cette caisse d'épargne et de crédit est situé à Drummondville, Québec, dans le district électoral de Drummond.Québec, le 15 avril 1900.Le Sous-secrétairc de la province.14778-0 Raymond Dou ville.Caisse Populaire de Schefferville (Lot des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le secrétaire de la province u approuvé la formation do la caisse d'épargne el de crédit « Caisse Populaire do Schelfervillo .Le territoire dans lequel la caisse recrutera ses membres sera la ville de Schelfervillo.Le siège sooial de cette caisse d'épargne et de crédit est situé à Schefferville, Québec, dans le district électoral de Duplessis.Québec, le 15 avril 1900.Le Sous-secrétairc de la province.11779-0 Raymond Dor villi:.Caisse d'Économie des travailleurs de Drummondville ( Saving and (redit Unions Act) Notice is given that the Provincial Secretary has approved the formation of the savings and credit union \"Caisse d'Economie des travailleurs de Drummondville\".The group in which the union will recruit its members will be the employees of the companies St-Francis Teinture.Eagle Pencil and Eastern Paper Box.The head office of this savings and credit union is situated at Drummondville, Quebec, in the doctoral district of Drummond.Quebec, April 15.1966.Raymond Dor vii.i.k.1477S Assistant Secretary of the Province.Caisse Populaire de Schefferville (Savings and Credit ['nions Act) Notice is given that the Provincial Secretary has approved the formation of the savings and credits union \"Caisse Populaire do Schefferville\".The territory in which the union will recruit its members will l»e the town of Schefferville.The bead office of this savings and credit union is situated at Schefferville.Quebec, in the electoral district of Duplessis.Quebec, April 15.1966.Raymond Dor vii.i.k.14779 Assistant Secretary of the Province.Compagnies autorisées Companies Licensed à faire des affaires to do Business International Savings International Savings and Mortgage Corporation and Mortgage Corporation Avis est par les présentes donné que « International Savings and Mortgage Corporation », ayant sa principale place d'affaires à 257, rue Smith, Winnipeg, Manitoba, a obtenu du Secrétaire de la Province en date du 21e jour de Notice is hereby given that \"International Savings and Mortgage Corporation\", having its main place of business at 257 Smith Street Winnipeg, Manitoba, has obtained from the Provincial Secretary on the 21st day of March 2332 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql'fill EC, 23 avril 1066, OS' année, n 16 mars, îooo, une licence lui permettant «le faire affairée «lans la Province «le Québec en vertu «les dispositions «le la Loi dei Sociétés «le Prêts et de Placements, chapitre 380, S.H.Q.1004, que la principale place d'affaires «b- la compagnie «lans la province «le Québec est situé à 500 Est, Grande Allée, en la cité «le Québec et «pie son principal agent dans la Province est Monsieur André Desmeules, avocat, dont l«- bureau est situé à l'adresse ci-dessus ».Lee Procureurs de la compagnie, St-Laurent, Monaht, 14618-1 l-l-o Dbsmbules & Walters.Iluinac-lluiisella Machincr> Corporation Avis est donné qu'en vertu de la Loi «les compagnies étrangères, la compagnie « Hamac -Hansella Machinery Corporation .a «:té autorisée à faire affaires «lans la province.L'agent principal, aux fins «le recevoir les assignations «lans les procédures contre ladite compagnie, est AI.Bronson Cuber, ch., s advocate, at the above given address.\" ST-laurent, Monast.Dksmkli.ks Si Walters, 14618-14-4-0 Attorneys for the company.IInmuc-llunscllu .Machinery Corporation Notice is given that under the Extra-Proviil cial Companies Act, \"Ilamac-IIausella Machinery Corporation\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company i> Air.Bronson Culver, q.c\u201e «>f 800 Victoria Square, Montreal.The principal office of the company in the Province is at 50 Cirinazie boulevard West, Montreal, judicial distru-t of Montreal.Raymond Dor villi;, Assistant Secretary of the I'rovina .14726m 13-66 \u2014 1314 50 Texas Instruments liu'orporatc*! Notice is given that, under the Kxt ra-Provin cial Companies Act, \"Texas Instruments In corporal «'d\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.W.IL Laidley, of Room 1100, 231 St.James Street West, Alontreal.The principal office of the company iu the Province is at Room 1100, 231 St.James Street West.Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Doivillk.Assistant Secretary of the Province.14725-0 ' 11-00 \u2014 1314 115 Chartes Abandon de Jane Apartments Ltd.Avis est par les présentes donné que « Jan«> Apartments Ltd., a l'intention «le demander au Secrétaire «le la province la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 12 avril 1000.Le Secrétaire, 14726-0 AIohtimku Dbckelbaum.Dolphin Swimwcar Inc.Avis est donné que la compagnie « Dolphin Swimwear Inc.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la ville de Montréal, s adressera au Secrétaire de la province «le Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté ù Montréal, ce 12e jour «l'avril 1900.Le Secrétaire, 14740 Harold DfiRMER.Charters Surrender of Jane Apartments I.id.Notice is hereby given umler the Quebec Companies Act and amendments that \".lain Apartments Ltd.\", intends t«> make application to the Provincial Secretary for leave to surrender its charter.Alontreal, April 12, 1900.AIoHTIM br 1 > kckklh al'.M, 14726-0 Secretary.Dolphin Swimwear Inc.Notice is hereby given that \"Dolphin Swim wear Inc.\", a corporation incorporated umler the Quebec Companies Act ami having its bead office in the city of Montreal, will apply to the Provincial Secretary of the Province «>f Quebec for leave to surrender its charter umler the provisions fo the Quebec Companies Act.Dated at Montreal, this 12th day «>f April.1900.Hahold Dermbr, I4740-o Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April S3, 1906, Vol.98, No.16 2838 < hanil)l\\ Lands Limited Avis est par lei présentes donné que « Chum-Icy Lands Limited », une compagnie constituée en corporation sous l'empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la cité et district de Montréal, province de Québec, s'adressera au Secrétaire de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec, Montréal, ce 14c jour d'avril.I960.Le Secrétaire-trésorier, Antoine Prévost.14738-0 12964-61 Le Curling Si Hyacinthe Incorporée Prenez avis que la compagnie « Le Curling St Hyacinthe Incorporée », demandera au Secrétaire de la province la permission d'abandonner sa charte.Le Procureur de la comjxignie.14730-Q Me Michel Potriei .Moiintview Pluxa Inc.Avis est donné que la compagnie « Mount view Plaza Inc.», tine corporation constituée en vertU «le la Loi «les compagnies de Québec et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au Secrétaire de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies «le Québec.Daté à Montréal.«\u2022«\u2022 13e jour «l'avril 191)6.Le Secrétaire.I 1763 ester wohl.Terrebonne Invest incuts Inc.Avis est donné que la compagnie « Terrebonne In vestments Inc.», une corporation constituée en vertu de la Loi «les compagnies «le Québec et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au Secrétaire «le la province «le Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte et son annulation à compter «l'une «late à être fixée par lui.Terrebonne Investments Inc., Par le Président, 14754 Pu ko a Dkckki.baim.Arba Corp.Avis est donné «pie la compagnie « Arba Corp.», une corporation constituée en vertu de la Loi «les compagnies de Québec, et ayant son >iège social en les ville et «listrict «le Montréal, s'adressera au secrétaire «le la province «le Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions «le la Loi des compagnies «le Québec.Daté à Alontréal.ce 28e jour de mars 196b.11764 Arba Corp.Les Procureurs de la compagnie, Tinkoff.Skaï., ShaposnICK & Moscowitz.Les Immeubles Cimon Inc.Prenez avis «pie la compagnie « Les Immeubles Cimon Inc.», demandera au Secrétaire «le lu Province la permission «l'abandonner sa charte.Le Notaire et Procureur, 14766-e AIk Lomkk Gervaib.Chambly Lands Limited Notice is hereby given that \"Chambly Lands Limited\", a company incorporated umler the provisions of Part I of the Quebec Companies Act and having its head office in the city and district of Montreal.Province of Quebec, will apply to the Provincial Secretary of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies Act.Alontreal.this 14th day of April, 1960.Antoine Prévost, Secretary-Treasurer.14738-0 12954-61 Le Curling St Hyacinthe Incorporée Take notice that \"Le Curling St Hyacinthe Incorporée*', will apply to the Provincial Secretary for Leave to surrender its charter.14739 AIi: Michel Pothikr, Attorney for the company.Mountview Plaza Inc.Notice is hereby given that the \"Alountview Plaza Inc.\".a corporation constituted under the Quebec Companies Act ami having its bead office in the city of Alontreal, will apply to the Provincial Secretary of the Province of Quebec for leave to surrender its charter umler the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Alontreal.this 13th «lay of April, 1906.KsTKU wohl, 14753-o Secretary.Terrebonne Investments Inc.Notice is hereby given that \"Terrebonne Investments Inc.\", a corporation constituted umler the Quebec Companies Act and having its beat! office in the city of Montreal, will apply to the Provincial Secretary of the Province of Quebec for the acceptance of the surrender of its charter ami its cancellation on and from a date to be fixed by him.Terrebonne Investments Inc., Per: Frkda Dkckklbaum, 14754-o President.Arba Corp.Notice is hereby given that \"Arba Corp.\", a corporation incorporated umler the Quebec Companies Act ami having its head office in the city and «listrict of Alontreal, will apply to the Provincial Secretary of the Province of Quebec for leave to surrender its charter umler the provisions of the Quebec Companies Act.Dated at Alontreal.this 28th «lay of March, 1900.Arba Corp., Tixkofk.Seal, Shafosnick & Moscowitz.14704-o Attorneys for Petitioner.Les Immeubles Cimon Inc.Take notice that \"Les Immeubles Cimon Inc.\", will apply to the Provincial Secretary for leave to surrender its charter.14700 AIk Lomkk (ïkhvais, Notary and Solicitor. GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 98 avril 1968, 98' année, nc m 2334 Huron-British Footwear Ltd.Avis est donné que » Huron-British Footwear Ltd.corporation constitués en vertu de la Loi des compagnies de Québec, s'adressera au secrétaire de la Province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de In Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 13e jour d'avril.1066.Le Secrétaire.14765-0 William Wiivtk.Niiinir lue.Prenez avis que la compagnie « Nomic Inc.demandera au Secrétaire de la Province la permission d'abandonner sa charte /.c Notaire et Procureur.14787-0 Mb Lombh Gbrvaib.Pâtisserie Coiisln lue.Avis est donm; que la compagnie « Pâtisserie Cousin Inc.\\ une cor|x>ration constituée en vertu de la lx>i des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au secrétaire de la province de Québec, afin d'obtenir la perniission d'al>andoimer sa charte, et son annulation à compter d'une date (pi'il lui plaira de fixer.Daté à Montréal.P.Q., le lôe jour d'avril, 1900.Le Secrétaire, 14768m Clauoe Bouvbt.Bienville Inc.Avis est par la présente donné que la compagnie « Bienville Inc., constituée en corporation dans la province de Québec par lettres patentes en date du lie jour de mars 1965, et ayant son siège social dans la cité de Alontréal.a établi son siège social au numéro lllô ouest, rue Sherbrooke, dans la cité de Alontréal.A compter de la date du présent avis, ledit siège social est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Alontréal, ce 25e jour de janvier 1000.(Sceau) Le l'résident.Dam N.Glumicich.14760m 1112-65 H rook 0c Id Corporation Avis est donné par les présents que * Brook-field Corporation1, demandera la permission d'abandonner sa charte à compter d'une date à être fixée.Brook fie Id ( Corporation, Par le Secrétaire.14788m E.S.Bercer.Lu Compagnie Kcgal Limitée Kegal Company Limited Prenez avis (pie « I«a Compagnie H égal Limitée H égal Company Limited », constituée en corporation en vertu de la loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la ville de Alontréal, s'adressera au Secrétaire de la Province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la loi des compagnies de Québec.Daté à Québec, ce dix-neuvième jour d'avril 1906.Le Procureur de la compagnie, 147S9-0 ALk .Ik an poitras, notaire.Huron-British font wear Ltd.Notice is hereby given that \"Huron-Britisli Footwear Ltd.\".a corporation incorporated Under the Quebec Companies Act will apply le the Provincial Secretary of the Province o| Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies Act, Dated at Alontreal.this 13th day of April I960.William Whttr, 14765m Secretary, Nomic Inc.Take notice that \"Noinie Inc.\".will apply to the Provincial Sectetary for leave to surrender its charter.All-: Lo.mKit GKRVAIS, 14767 Notary and Solicitor, Pâtisserie Cousin Inc.Notice is hereby given that \"Pâtisserie Cousin Inc.\", a corporation constituted under tlic Quelle Companies Act and having its head oilier in the city of Montreal, will apply to the Bec i tary of the Province of Quebec for the acceptance of the surrender of its charter and its cancellation on and from a date to Ik- fixed by him.Dated at Alontreal, P.Q.the lôth dav of April, 1900.Claude Bouvbt, 1470S-o Secretary.Bienville Inc.Notice is hereby given that the company \"Bienville Inc.\", incorporated in the province of Quebec by letters patent on the 11th day of March, 1065, and having its heat! office in I In-city of Alontreal.has established its head office at number lllô Sherbrooke Street West, iu the city of .Montreal.From and after the date of this notice, the said head office shall !>e considered by the company as being the head office of the company.Given at Alontreal, this 25th dav of January 1066.(Seal) Dan N.glumicich, President.14700-o 1112-63 Brookficld Corporation Notice is given hereby that \"Brookficld Corporation\", will make an application for leave to surrender its charter from and after a date to be fixe»I.Brookficld Corporation.Per: k.S.BerOER, 14788 Secretary.Kcgal Company Limited La Compagnie Regal Limitée Notice is hereby given, that \"Kegal Company Limited La Compagnie Kegal Limitée\", a corporation constituted under the Quebec Companies Act and having its head office in the < ity of Alontreal.will apply to the Secretary of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quel ec ('ompanies Act.Dated at Quebec, this nineteenth dav of April 1900.Ah: JbAM Poitkas.notary.14780m .Utorncp for the com pan j/. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 88, 1966, Vol.08, No.16 2335 Normandie Gardens Corp.Avis est donné pur les présents que * Normandie Gardens Corp,», demandera la permission d'abandonner sa charte à compter d'une date » être fixée.Normandie Gardens Corp., Far le Secrétaire.i 1790-0 ES.S.Berger.Normandie Gardens Corp.Notice is hereby given that ''Normandie Gardens Corp.\", will apply for leave to surrender its charter from and after a date to be fixed.14790 Normandie Cardens Corp.Per: K.S.Bi:iu;i;n, Secret ar u.Itadcl Realty Inc.Avis est donné que la compagnie « Rade] Realty Inc.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social eu la ville de Montreal, s'adressera au secrétaire de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'ahandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 4e jour tic mars 1966.\"91 Le Président.M.mj: Ln.v Coiikn.Rudel Realty Inc.Notice is hereby given that \"Radel Realty Inc.\", a corporation incorporated under the Quebec Companies Act ami having its head office iu the city of Montreal, will apply to the Provincial Secretary of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies Act.Dated at Alontreal.this 4th dav of Alarch.1966.AI us.Ln.v Coiikn, 14791-0 President.Compagnies dissoutes Companies Dissolved Vrgenteiiil Cable Vision Inc.Avis est donné qu'en vertu de la Iah «les compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de \" Argenteuil Cable Vision Inc.», constituée en corporation le Kl septembre 1959, à compter du IS avril 1966.Le Sous-secrétairc de la province.Raymond Dor vii.i.k.14725-0 15281-50 Ra> ridge Estates Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la Loi «les compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de « Bayridge Kstates Ltd.», constituée en corporation le 7 novembre 1051, à compter du 18 avril 1066.Le Sous-secrétairc de la prorince.Raymond Doi villk.i 172Ô-0 13760-51 Rourget Construction lue.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il u plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de « Rourget Construction Inc.», constituée en corporation le 28 février 1052, à compter du 18 avril 1066.Le Sous-secrétaire de la prorince.Raymond Doivillk.i 1725m 3804-52 S.Cadieux & fils ltée Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de « S.Cadieux & fils ltée », constituée en corporation le '.i avril I960; à compter du IS avril 1966.Le Sous-secrêtaire de la province.Raymond Douvillk.I4725-0 10984-66 Canadian Dinette Co.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province Argenteuil Cable Vision Inc.Notice is given that, under the Companies Act.the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Argenteuil Cable Vision Inc.\", incorporated on September 16, 1959.on and from April IS.1066.Raymond Doi -villi-;.Assistant Secretary of the Province.1472Ô 1Ô2SI-Ô9 Rayridge Kstates Ltd.Notice is given that, umler the Companies Act.the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Bay-ridge Estates Ltd.\", incorporated on November 7.1051, on and from April IS, 1900.Raymond Doivillk.Assistant Secretary of the Province.14725 13709-01 Rourget Construction Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Rourget Construction Inc.\", incorporated on February 28, 1052, on and from April IS.1900.Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.14725 3894-62 S.Cadieux & fils ltée Notice is given that, under the Companies Act.the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"S.Cadieux & fils ltée\", incorporated on April 3, 1900.on and from April 18, 1000.Raymond Doivillk.Assistant Secretary of the Province.14725 10084-66 Canadian Dinette Co.Notice is given that, under the Companies Act.the Provincial Secretary has been pleased 2336 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, $9 avril 19(iti, OS\" aimée, n° 16 d'accepter l'abandon de la charte de * Canadian Dinette Co.», constituée en corporation le 10 février 1001.à compter du 1S avril 1900.Le Sons-sec refaire de la prorince, Raymon i» Douvillk.14725*o 557-64 to accept the surrender of the charter of \"Caua dian Dinette Co.\".incorporated on February Ml 1904, on and from April IS.1900.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.1472Ô 557.6-1 Causent Rtiilding Limited Avis est donné qu'en vertu «le la Ix>i des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon «le la charte «le « Causent Building Limited », constituée en corporation le 4 août 1053, à compter «lu 1S avril 1966.Le Sons-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.14725m 10107-53 Causent Rtiilding Limited Notice is given that, under the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Causent Ruilding Limited\", incorporated on August I, 1053, on and from April IS, 1966.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 16167.53 Carl et on Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi «les compagnies, il a plu au secrétaire «le la province «l'accepter l'abandon «le la charte de « Carleton Holdings Inc.s, constituée en corporation le 13 mai 1000, à compter «lu 1S avril 1066.Le Sous-secrétairc de la province, Raymond Douvillk.14725m 12157-00 Carleton Holdings lue.Notice is given that, under the Companies Act, the Provincial Secretary has l>een pleased to accept the surremler of the charter «»f \"Carleton Holdings Inc.\", incorporated on May 13, I960, on and from April IS.1000.Raymond Dor villk.Assistant Secretary of the Province.14725 12157-00 La Cie d'Auteuil ltée D'Auteuil Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu «!<\u2022 la I/>i des compagnies, il a plu au secrétaire de la province «l'accepter l'abandon «le la charte «le « La Cie d'Auteuil ltée - D'Auteuil Co.Ltd.», constituée en corporation le 19 novembre 1058, à compter du 18 avril 1900.Le Sous-secrétairc de la province, Raymond Douvillk.14725-0 14162-58 La Cie d'Auteuil liée D'Auteuil Co.Ltd.Notice is given that, umler the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased t<> accept the surrender of the charter of \"La Cie d'Auteuil ltée \u2014 D'Auteuil Co.Ltd.\", incorporated on November 10, 1958, on ami from April 18, 1000.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 14162-58 Code Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la Ix>i des compagnies, il a plu au secrétaire de la province «l'accepter l'ai «union de la charte de « Code Realties Ltd.», constituée en corporation le 12 juillet 1954.à compter du 18 avril 1900.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Dou villk.14725-.) 11836-54 Code Realties Ltd.Notice is given that, nder the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased t<> accept the surrender of the charter of \"Code Realties Ltd.\", incorporated on July 12, 1054, on and from April 18, I960.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 11830-51 Continental Sewing Machine Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de « Continental Sewing Machine Co.Ltd.», constituée en corporation le 5 décembre 1951, à compter «lu 18 avril 1000.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.14725-0 14908-51 Continental Sewing Machine Co.Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of 'Continental Sewing Machine Co.Ltd.\", incorporate*! on December 6, 1051, on and from April 18, 1900.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.14725 14068-51 Kugcne Desjardins, Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province «l'accepter l'abandon «le la charte «le « Eugène Desjardins, Ltd.».constituée en corporation le 2 septembre 1930.à compter du 18 avril 1960.Le Sous-secrêtaire de la prorince, Raymond Dou villi-:.14725-o 1671-30 Eugène Desjardins.Ltd.Notice is given that, umler the Companies Act, the Provincial Secretary, has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Eugène Desjardins, Ltd.\", incorporate*! on September 2, 1930, on and from April 18, 1900.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Prorince.14725 1671-30 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, lUCH, Vol.98, No.W 2337 Kldu Jewellery Manufacturing < lompaii} Limited Avis est donné qu'en vertu tie la Loi des coin-pagines, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de « Klda Jewellery Manufacturing Company Limited », constituée en corporation le 2 août 1003, à compter «lu 18 avril I960.Le Sou s-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.1172.V.» 3318-63 liilcrsigs ltée Avis est «humé qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire «le la province d'accepter l'abandon de la charte de « intersigs ltée ».constituée «'il corporation le 21 juin 10(12, j compter «lu 18 avril 1066, Le Sous-secrétairc de la province, Raymond Douvillk.i 1726-0 12703-02 W.Klaar (Canada) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire «le la province d'accepter l'abandon «le la charte «le « \\Y.Klaar Canada) Ltd.», constituée en corporation le .'! avril 1046, à compter du 18 avril 1900.Le Sous-secrêtaire de la proriiice.Raymond Douvillk.11725-0 2077-45 Laurence Fabrics Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la Loi «les compagnies, il a plu au secrétaire «le la province d'accepter l'abandon de la charte «le « Lawrence Fabrics Ltd.».constituée en corporation le 6 novembre 1902.si compter «lu IS avril 1066.Le Sous-secrêtaire de la prorince, Raymond Douvillk.i 1725-0 14468-02 Jos Leblanc limitée Avis est donné qu'en vertu de la ix>i des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte «le « Jos Leblanc limitée », constituée en corporation le 3 mars 1961, à compter du 18 avril 1900.Le.Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.11725-0 10S54-01 London Garage Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de « London Garage Ltd.», constituée en corporation le 14 juillet 1953, à compter du 18 avril 1966.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.11725-n 15850-53 Macon Investments Limited Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province «l'accepter l'abandon de la charte de « Maçon Investments Limited », constituée en corporation le 6 novembre 1940, à compter du 18 avril 1900.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Dou villk.11725-0 7605-40 Klda Jeweller) .Manufacturing Coin pan > Limited Notice is given that, umler the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender «if the charter of \"Klda Jewellery Manufacturing Company Limited\", incorporated on August 2.1068, on and from April 18.1000.Raymond Dou villk, .Issistunt Secretary of the Province.14725 3318-03 Intersigs liée Notice is given that, under the Companies Act.the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender «tf the charter of \"Intersigs ltée\", incorporated on June 21.1062, on and from April 18, 1000.Raymond Doi villi;.Assistant Secretary of the Prorince.14725 12703-02 W .Klaar (Canada) Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"W.Klaar (Canada) Ltd.\", incorporated on April 3.1945.on and from April 18, 1900.Raymond Doi villi;.Assistant Secretary of the Province.14725 2077-45 Law ronce Fabrics Ltd.Notice is given that, umler the Companies Act.the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Lawrence Fabrics Ltd.\".incorporated on November 6, 1902, on and from April 18.1900.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Prorince.14725 14468-62 Jos Leblanc limitée Notice is given tliat, under the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Jos Leblanc limitée\", incor|>orated on Alarch 3, 1961, on and from April 18, 1960.Raymond Douvillk, Assistant^Secretary of the Province.14725 10854-01 Loudon Garage Ltd.Notice is given tliat, umler the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"London Garage Ltd.\", incorporated on July 14, 1953, on and from April 18, 1906.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 15S50-53 Macon Investments Limited Notice is given that, under the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Macon Investments Limited\", incorporated on November 6, 1946, on and from April 18, 1966.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.14725 7665-40 2338 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql'ÊHEC, 23 avril KMC,, fw« année, n Hi Maçonnerie moderne lié** Modern Masonry Ltd.Avis est donné qu'en vertu de lu l/oi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon «le la charte «le « Manon- neric moderne ltée Mo«lcrn Masonry Lt«l.», constituée en corporation le 1er juin 1005, à compter «lu 18 avril 1966.l.c Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.14725-0 2618-65 Maçonnerie moderne liée Modern Musonry I.id.Notice is given that, under the ('oinpauii -Act, the Provincial Secretary has l>ecn pleased to accept the surrenih-r of the charter of \"Maçon nerie moderne ltée \u2014 Modern Masonry Ltd.\", incor|m)rate«l on June 1.1965, on and fr«>m April IS, 1966.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.1172Ô 2618-0.\") Muplcdalc Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu «le la I/)i «les compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon «le la charte de « Maplcdalc Investment Cor|M)ration ,s, COnitituée en cor|>o-ration le 25 mai 19.\">\">.à compter «lu 1S avril 1000./.c Sous-secrétairc de la province, Raymond Doivillk.14725-0 11402-55 Marlhonmgh Coll'tK Country Club.Limited Avis est donné qu'en vertu «le la Loi «l«-s compagnies, il a plu au secrétaire «le la province d'accepter l'abandon ecn pleased to accept the surremler of the charter of \"AlapK «laie Investment Corporation\", incorporated on May 25, 1956, on ami from April IS, I960.Raymond DoUVILLB, Assistant Secretary of the I'rovinc,.1472Ô 11402-50 Marlborough Coll a Country Club, Limited Notice is given that, under the Companies Act.the Provincial Secretary has been pleased t«> accept the surrender of the charter of \"Mini borough (i«>lf & ( taunt ry ( luh.Limited\", incorporated on February 7.102)1.on ami from Api il IS.1900.R \\ ymon i) I )«)! vi l.l.l .Assistant Secretary of the I'rarinti .1172.\") 192-23 Maltolt Investments Limited Avis est donné qu'en vertu «le la Loi des companies, il a plu au secrétaire «le la province d'accepter l'abandon «le la charte «le « Mattolt Investments Limited .constituée en corporation le 11 mai 1964, à compter «lu ls avril 1966.Le Sous-secrétaire de la prorince.Raymond Doi villk.1472Ô-0 1048-64 Mutiolt Investments Limited Notice is given that, umler the Companies Act.the Provincial Secretary has been pleased t«) accept the surrender of the charter «»f \"Slat toll Investments Limited\", incorporate*! on Maj 11.1064, on ami from April IS.1066, Raymond Dou VILLK, Assistant Secretary nf the I'roriiice.1472.\") 1048-64 The Me bee Company, Limited Avis est donné qu'en vertu de la Loi f the charter of \"Modern Stucco & Terra/./o Co.Ltd.\", incorporated on February 28, 1047.on and from April IS, 1066.Raymon d Doi villk, Assistant Secretary of the I'mrinct 1472.\") 2122-17 M on ii i ii i m City Motors Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la Loi «les compagnies, il a plu au secrétaire «le la province «l'accepter l'abandon «le la charte «le « Mountain Mountain City Motors Ltd.Notice is given that, umler the Companw- Act.the Provincial Secretary has been pleased lo accept the surremler of the charter of \"Mountain QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 88, 1966, Vol, us.No.m 2339 City Motors Ltd.constituée en corporation le 7 février 1003, à compter du 18 avril i960.Le SoUS-Becritaire de hi Prorince.Raymond Douvillk.i 1725-0 610.03 Nrw York Investment (Corporation Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon «le la charte «!«' * New York Investment Corporation .constituée en corporation le 21 mai 1956, à compter «lu 18 avril 1966.Le SoUS-seerétaire de la prorince.Raymon d Douvillk.14725-0 11376-55 Park Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire «le la province d'accepter l'abandon de la charte de « Park Holdings Lt«l.constituée en corporation le lô novembre 1946, à compter du 18 avril 1906.Le SoUS-secrétaire de la prorince.Raymond Douvillk.i I725-0 7747-40 Pointe Claire Itarhecue «\\ Spaghetti House Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la Loi «les compagnies, il a plu au secrétaire «le la province d'accepter l'abandon «le la charte «le « Pointe (lain- Barbecue & Spaghetti House Inc.constituée «mi corporation le s novembre 1954, à \u2022 ompter «lu IS avril 1966.Le Sous-secrêtaire de la prorince.Raymon d Douvillk.14725-0 I2707-Ô-1 Quebec Cinema Scope T.Y.Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la Loi «les compagnies, il a plu au secrétaire «le la province d'accepter l'abandon .1946.«m and from April IS.1066.Raymon d Douvillk, Assistant Secretary of the Prorince.1472Ô 7747-40 Pointe Claire Burhccuc & Spaghetti House Inc.Notice is given that, under the Companies Act.the Provincial Secretary has been pleased to accept the surremler of the charter of \"Pointe Claire Barbecue & Spaghetti House Inc.\".incorporated on November 8, 1054, on and from April IS.1900.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Prorince.I472Ô 12707-04 Quebec Cinema Scope 'I'.V.Ltd.Notice is given that, umler the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter «>f \"Quebec Cinema Scope T.\\.Ltd.\", incorporated on April 1.1904.on and from April IS.1900.14725 Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Prorince.1496-64 Divers Compagnies .Miscellaneous Companies Béliveau Pattcrnworks Inc.Avis est donné «pie la compagnie « Béliveau Patternworks Inc.a changé le nombre «le ses administrateurs «le 4 à 3.Le Secrétaire.Mmi; Hknhikttk Gagnon Bki.ivkai.! I727-o 4580-65 St.Joseph's House of Hospitality Inc.\\\\is est «l«)inié «pie le secrétaire «le la province il.h' 0 avril 1000.approuvé les règlements généraux de «St.Joseph's House of Hospitality Lu-.et ce.en vertu «le l'article 225 de la Loi des compagnies.Le Sous-secrétairc de la prorince.Raymond Douvillk.14729-0 1062-65 Béliveau Patternworks Inc.Notice is hereby given that \"Béliveau Pattern* works Inc.\".has changed tin- number of its directors from 4 to 3.Mns.Hknuikttk Gaunon Bki.ivkai.Secretary.14727 4580-65 St.Joseph's House of Hospitality Inc.Notice is hereby given that the Provincial Secretary has.on April 0.1966, approved the general by-laws of \"St.Joseph's House «>f Hospitality Inc.\", and such, in pursuance to section 22ô of the Companies Act.Raymond Douvillk, Assistant Secretari/ of the Prorince.14720 1902-0.\") 2340 GAZETTE OFFICIELLE DE QCÉ11EC, ;>S avril lOfili, OS' année, n\" W Coopéra tio inc.Avis est donne que lu compagnie « Coopérât in inc.», a changé le nombre dé ses administrateurs de 3 4 14, Le Secrétaire.BERNARD TruDKL.14728.0 \u2022 4172-04 Le Club de chasse à tir de Québec Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 12 avril 1000, approuvé les règlements généraux de « Le < Hub de chasse à tir de Québec .et ce, en vertu de l'article 220 de la Loi des compagnies.Le Sous-secrétaire de la prorince.Raymond Douville.1474 l-o 934-00 Creative Photographers Ltd.Avis est donné que la compagnie «Creative Photographers Ltd.a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.Le Président.(i.H.Ferguson.14742 13351-02 De-Mix liée Avis est donné que la compagnie « De-Alix ltée , a changé le nombre de ses administrateurs de l à 3.Le Secrétaire.Bernard Diuk.14743.0 4930-04 kehal Israel Association Inc.Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 7 avril 1900, approuvé le règlement minier») 1 de « Kehal Israel Association Inc.», et ce.en vertu de l'article 220 de la Loi des compagnies.14744-0 Le Sous-secrétaire de la prorince.Raymond Dor villk.725-66 Les Loisirs paroissiaux de Sault-aii-Mouton inc.Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 7 avril 1966» approuvé les règlements généraux de « Les Loisirs paroissiaux de Sault-au-M out ou inc.», et ce.en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Doiville.14745-0 533-00 Les Producteurs de lait nature de Montréal inc.Avis est donné (pie Je secrétaire de la province a, le 5 avril 1900, approuvé les règlements généraux de « Les Producteurs dé lait nature de Alontréal inc.», et ce, en vertu de l'article 225 «le la Loi des compagnies.Le Sous-secrétairc de la prorince.Raymond Dor villk.14740-e» 3986-65 Hell Aluminum Industries Ltd.Avis est donné que la compagnie « Bell Aluminum Industries Ltd.», a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le Secrétaire, Reuben Zimmerman.14755 554-05 Coopérai io inc.Notice is hereby given that « Coopéraii« inc.\", has changed the number of its directors from 3 to 14.Bernard Trudel, Secretari/.1472s 1172-1.1 Le Club de chasse à tir de Québec Notice is given that the Provincial Sécrétai;, has, on April 12.1966, approved the general bj laws of « Le Club de chasse à tir de Québec .and such, in virtue of section 220 of the Companies Act.Raymond Doivillk, Assistant Secretarif of the Prorince.14741 934-60 Creative Photographers Lid.Notice is given that \"Creative Photographer* Ltd.\", has changed the number of its directors from 5 to 3.G.R.Ferouson, Président.14742-0 13351-62 De-Mix ltée Notice is given that \"De-Alix ltée\".hasehan.ed the number of its directors from I to 3.14743 Bernard Dubé, Secretari/.4936-64 kehal Israel Association Inc.Notice is hereby given that the Provincial Secretary has.on April 7.1900.approved by-law number 1 of \"Kehal Israel Association Inc.\", and such, in pursuance to section 220 of the ( 'ompanies Act.Raymond Doivillk.Assistant Secretarif of the I'roriiice.14744 726-66 Les Loisirs paroissiaux de Saull-au-Moutoo inc.Notice is given that the Provincial Secret an has.on April 7.1900, approved the general bylaws of \"Les Loisirs paroissiaux de Sault-au-Mouton inc.\".and sudl, in virtue of section 22\") of the Companies Act.Raymon d Dor villi.Assistant Secretarif of the Prorince.14745 533-6(1 Les Producteurs de luit nature de Montréal inc.Notice is hereby given that the Provincial Se-cretary, on April 5, 1900, approved the general by-laws of \"Les Producteurs de lait nature «b Alontréal inc.\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Raymond Dor villi.Assistant Secretarif of the I'roriiice.14740 3986-60 Hell Aluminum Industries Ltd.Notice is given that \"Hell Aluminum Industries Ltd.\", has changed the number of its directors from 4 to 3.Ib:i ui:n Zimmerman, Secretary'.14755-o 554-1 if) QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 98, 1906, Vol, 98, No.JO 2341 Compagnie de Fiducie Prêt et Revenu Savings unci Investment Trust Company Avis est donné que la « Compagnie de Fiducie Prêt et Revenu 'Savings and Investment Trust Company-, a changé le nombre «le ses administrateurs de 13 à lô.Le Secrétaire, A SDH F.VEROK.I47ôO-<> 782-60 I.empira Mines, i.ld.(No Personal Liability) Avis est donné (pie la compagnie * Leinpira Mines, Ltd.», (No Personal Liability) a changé le nombre de ses administrateurs de (1 à 3.Le Secrétaire.C,.E.ALDanikl.U7.\">7 11415-57 Purkdale (1965) Inc.Avis est donné «pie la compagnie « Parkdule (1965) Inc.», a changé le nombre de ses adminis-I rateurs «le 3 à 4.Le Secrétaire.IL Robert Grebniield.! 1758 6010-65 Key go 'ii u ni inc.Avis est donné que la compagnie * Reygo Vacuum inc.», a changé le numhre de ses administrateurs ec en date du 9e jour de mai 1923, et ayant son bureau principal au numéro 1450 rue city Councillors Alontréal, a transporté son bureuu principal au numéro 7000 rue l'arc Montréal.À compter du premier jour de février ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Sherbrooke, ce septième jour d'avril 1066.Le Sécrétaire-trêsorier, i 174&0 I.L.Dt7Gan.Ke\\go \\ aciium inc.Avis est par les présentes donné que « Reygo Vacuum Inc.», a changé son siège social de 6795, rue St-l'rbain, à Alontréal, à 12,0X0, Boulevard Laurentien, en la cité de Montréal.Montréal, 29 mars 1066.(Sceau) Le Secrétaire.! 1709-e» Lilianne Lacson.Star Brush Itée-Ltd.Avis est donné que la compagnie ¦ Star Brush ltée Ltd., a changé son siège social de Montréal, au numéro 7055, boulevard St-AIichcl.en la .ité de St-Alicbel.Le Secrétaire.Laurette Dupuib Lemay.h70i-o 12360-65 letters patent on the 9th day of May, 1923, and having its head office in the city of Alontreal, Province of Quebec, situated at civic inn n I mm 1450 city Councillors Street, has moved its head office to civic number 7000 Park Avenue.From and after the first day of February, the said office shall l>e considered as being the bead office of the company.Given at Sherbrooke, this seventh day of April, 1000.1.L.duqan, 1 174X-o Secretary-Treasurer.Ke>go Vacuum inc.Notice is hereby given that \"Reygo Vacuum Inc.\".has changed its head office from 070.5 St-t'rhaiu Street, in Montreal, to 12,0X0 Laiiren-tien Boulevard, in the city of Montreal.Alontréal.March 20.1900.(Seal) Lilianne Lai /.on.11759 Secretary.Star Brush Itée-Ltd.Notice is given that \"Star Brush ltée Ltd.\".has changed its head office from Alontreal, to number 79.55 StAIichel Boulevard, in the city of St-Michel.Laurette Dvpuis Lemay, Secretary.14701 12350-55 Marché Lachance lue*.Avis est donné epic la compagnie « Marché Lachance Inc.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, en date du 7 mars 1900, et ayant son bureau principal à Montréal, province de Qllébec, a établi son bureau au numéro 1203 rue Jean-Talon est.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 28e jour de mars 1000.11770m Le Président.Nazaire Lachance.1028-66 Marché Lachance Inc.Notice is given that \"Marché Lachance Inc.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies Act, dated March 7.1966, and having its principal office at Montreal, province of Queliec, lias established its office at number 1203 Jean-Talon Street East.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its principal office.Given at Montreal, this 28th dav of March.1066.Na/.aihk Lachance, President.1477(1 1028-66 Lcnioyne «\\ Crant Inc.Avis est par la présente donné que la compagnie Lemoyne & Grant Inc.», constituée en corporation dans la province de Québec, par lettres iintentes en date du 4e jour du mois de janvier I960, et ayant son siège social à S54 houl.Décarie dans la cité de Si - Laurenl.a changé son siège social au numéro 1343 rue du Collège, Ville si-Laurent, district de Alontréal.A compter de la date du présent avis, ledit siège social est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Alontréal, ce 27ème jour de décembre 1965.(Sceau) Le Président, lUm.nr G.Lemoyne.I4702-o 17005-50 Lemoyne & Grant Inc.Notice is hereby given that the company \"Lemoyne & Grant Inc.\", incorporated in the Province of Quebec by letters patent on the 4th day of the month of January 1060 and having its head office at S54 Decaric boul.in the city of St.Laurent, has changed its office to 1343 du Collège Street, city of St.Laurent, district of Montreal.From and after the date of this notice of change of address, the said office shall l>e considered by the company as being the bead office of the company.Given at Alontreal, this 27th dav of December 1065.(Seal) Robert G.Lemoyne, President.14792-o 17005-50 Les Productions Robard Inc.Avis est donné que lu compagnie « Les Productions Robard Inc.>, constituée en corporation par lettres patentes en date du 11 février 1966, Le- Production.* Robard Inc.Notice is hereby given that \"Les Productions Robard Inc.\".incorporated by letters patent dated February 11, 1900, and having its head 2344 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 23 avril 1066, 09* année, u° 16 et ayant son bureau principal à Montreal, a établi son bureau au 1255 «le la rue Université, chambre 120.A compter de lu date «lu présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme ('¦tant son bureau principal.Montréal, ce I avril, 1966, Le l'réside ni, Robert Rivard.I4703-o 5148-65 office in Montreal, has established its office al 1255 Université Street, Room 420.From and after the date of the present notice, the said oflice is considered by the company ax being its head oflice.Montreal, April 4, 1000.Robert Rivarp, President.11703 5148.65 Demandes à la Législature Ville de Pincourt Avis public est par les présentes donné que la « Ville de Pincourt», dans le comté de Vau-drcuil-SouIangcs, district de Montréal, s'adressera à la Législature de Québec, au cours de la présente session pour demander l'adoption d'une loi spéciale aux fins suivantes: Modifier ses règlements d'emprunts en vigueur lors de la sanction de la Loi 12-13 Elizabeth II, chapitre 53, pour prescrire que dans le cas des lots situés à un carrefour et de ceux qui ne sont pas rectangulaires, la Laxc spéciale peut être imposé en tenant compte à la fois de leur étendue en front et de leur superficie; et pour toutes autres fins.Pincourt, ce 22 mars 1900.L'Avocat de la requérante, 14401-13-4-o Maurice R.Marcotte.Applications to Legislature Town of Pincourt Public notice is hereby given that the \"Town of Pincourt\", in the county of Vaudrcuil-Sou-langes, in the district of Alontreal, will apply to the Legislature of the Province of Quel>ec, at its present session, to request the adoption of a special Act, for the following purposes: Amend its loan by-laws in force at the date of the sanction of the Act 12-13 Elizabeth II.chapter 53, to decree that in the case of lots tliat are situated at a street corner or are not rectangular, the council may fix the frontage for assessment purposes, taking into account Im)|Ii frontage and area; and for all other purposes.Pincourt, March 22, 1960.AIaurice R.Marcotte, 14401-13-4-o Attorney for the petitioner.Cité de Longueiiil Avis est par les présentes donné que la « Cité de Longueuil », corporation municipale ayant son siège social dans les limites de son territoire, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, aux fins d'obtenir les pouvoirs suivants: Autoriser la Cour municipale a livrer les .sommations de comparaître par courrier recommandé; autoriser les constables ou agents de la Paix à émettre un avis sommaire équivalant à une sommation de comparaître en Cour municipale dans les cas d'infraction aux règlements de circulation et sécurité publique; revendre pour lins résidentielles certaine lisière de terrains acquis suivant la Loi des fonds industriels; acquérir de toute corporation de la Couronne du chef du Canada certains terrains et les revendre sous certaines conditions; et pour toutes autres fins.Longueuil.ce 21 mars 1900.Le Procureur de la cité de Lonyucuil, 1450843-4-0 J.é1.01 Gbrvais, ch.City of Longueuil Notice is hereby given that the \"City of Longueuil\".municipal corporation having it-head office in the limits of its territory, will apph to the Legislature of the Province of Quebec.at its present session, for the purpose of obtaining the following powers: To authorize the Aluni cipal Court to deliver the service of process by registered mail; to authorize the constables or officers of the peace to issue a summary notice equivalent to a service of process in the Aluni cipal Court in cases of infraction to the public security and traffic regulations; to resell for residential purposes certain strip of lamb acquired according to the Industrial Funds Ad : to acquire from any Crown corporation in tin right of Canada certain lots of land and to resell them under certain conditions; and for all othei purposes.Longueuil, March 21, 1900.J.Éloi Gervais, q.c, 14508-13-4 Attorney for the city of Longueuil.St.Andrews Golf Club Inc.Antoine Paré, avocat, Pothier Ferland, avocat et Jean Archambault, étudiant présenteront un bill privé à la présente session de la législature de Québec pour rétablir les lettres patentes de « St.Andrews Golf Club Inc.».-Mars 25, 1966.Les Avocats et Procureurs, Paré, Ferland, AIackay, Barbeau, 14519-13-4-0 Holden & Steinberg.St.Andrews Golf Club Inc.Notice is hereby given that Antoine paré, lawyer, Pothier Ferland, lawyer and Jean Ai cliambault, student will present a private bill at the present session of the Quebec Legislature for the reinstatement of the letters patent of \"St Andrews Golf Club Inc.\".Alarch 25, 1966.Paré, Ferland, AIackay, Barbeau, Holden & Steinberu.14519- 13-4-o Barristers and Solicitors. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April S3, WW, Vol.98, No.10 2345 Cité de Hull Avis est par les présentes donné que la « Cité de Hull », s'adressera à la Législature de la province de Québec lors de sa présente session pour obtenir l'adoption d'une loi spéciale amendant sa charte pour les fins suivantes: Pour permettre au Conseil d'augmenter à 8 le nombre de quartiers et des échevins; Pour modifier les qualifications foncières nécessaires pour être candidat aux charges de maire et d'échevin; Pour modifier la date de la mise en nomination et de l'élection; Pour que le président du Conseil n'ait qu'un vote prépondérant; Pour (pie l'ouverture des soumissions soit faite par le comité exécutif; Pour modifier les exemptions de taxe sur certaines propriétés; Pour modifier les formalités relatives à l'octroi de franchise pour le transport urbain de passagers, et pour d'autres fins.Hull, ce 29iènio jour de mars 10(10.Le Muire, Marcel D'Amoi k.Le Greffier, i 1608-14-4-o Roland Stevens.City of Hull Notice is hereby given that the \"City ol Hull\".will present a petition to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, to obtain the adoption of a special law, amending its charter for the following purposes: To permit council to increase to K the number of wards and aldermen; To modify the necessary requirements to become a candidate for mayor or alderman; To change the nomination and election dates; To grant the chairman of council a deciding vote; To permit the executive committee to Open tenders for money by laws; To change the tax exemptions; To change the formalities in granting franchises for the transportation <>f passengers and for other purposes.Hull, this 20th day of March 1966.Marcel D'Amour, Mayor.Roland Stevens, 14608-14-4 City Clerk.Liquidation Avis de Winding up Notices la Caisse Populaire Dcsjardins de Saintc-Paiilc Avis est donné que.lors d'une assemblée générale spéciale des membres de « La Caisse Populaire Dcsjardins de Sainte-Paulc .tenue à Saiiile-Paule.le 21 décembre 1005.il a été résolu que les affaires de ladite caisse soient liquidées, et que celle-ci soit dissoute, le tout en vertu de la Loi des caisses d'épargne et de crédit et de la Loi de la liquidation des compagnies à fonds «octal, et que MM.René Deschènes.Albert Ouellet et Edgar L.Thériault ont été nommés liquidateurs./.c Sous-secrétaire de la prorince.Raymond Doiville.i 1734-0 2056-45 Ministère des Affaires îmmieipales Lu Caisse Populaire Desjardins de Sainte-Paule Notice is hereby given that, at a special general meeting of the members of \"ba Caisse Populaire Dcsjardins de Sainte-Paule\".held at Sainte-Panic, on December 21.1005.it has been resolved that the affairs of the said credit union he wound Up, and it be dissolved, the whole in virtue of the Savings and Credit 1 nions Act and of the Winding-up Act.and that MM.René Deschènes, Albert Ouellet and Edgar L.Thériault be named liquidators.Raymond Dor villi.Assistant Secretari/ of the I'roriiice.14734 20.50-45 Department of Municipal Affairs Ville de Rélair Règlement No B-l.', A l'effet de porter la durée du mandat du maire et des éçheVins de deux ans à trois ans.Assemblée régulière ajournée du conseil municipal de la corporation de Ville de Rélair, comté de Québec, tenue le 21ième jour de février 1900, à 8 heures du soir, à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle assemblée étaient présents* Son Honneur le inaire Gaston Robitaille.Messieurs les échevins: Albert Vallièrcs, Roméo Guénette, Paul-Emile Ross, Emmanuel I Rodrigue, Arthur Roy.Tous membres du conseil et formant quorum.Il est constaté (pic les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et à chacun des membres du conseil de la manière et dans le délai voulus par la loi.Town of Rélair By-law No.B-1J, Concerning the lengthening of the term of office of the mayor and aldermen from two to three years.Regular adjourned meeting of the municipal ( 'ouncil of the Corporation of the Town of Rélair.county of Quebec, held on the 21st day of February, 1000, at S:t)0 o'clock in the evening, in the place where Council meetings are usually held, at which were present: His Honour the Alayor Gaston Robitaille.Messrs Aldermen: Albert Vallièrcs, Roméo Guénette, Paul-Emile Ross, Emmanuel Dodri-gue, Arthur Roy.All members of the Council and forming quorum.It is established that the notices concerning the present meeting have been given to each and all the members of the Council in the manner and within the delay prescribed by lay. 2346 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 23 avril 1966, OS' année, n° 16 Considérant que lu corporation de lu Ville de Bélair u été incorporée en ville par lettres patentes, et est régie par les dispositions «le la Loi «les cités et villes du Québec, chapitre 193 S.H.Q.1964; considérant que la durée du mandat de son honneur le maire et de messieurs les échevins est actuellement de deux ans et qu'il serait avantageux pour la corporation, afin d'améliorer la permanence de l'administration municipale.de porter la durée (le ce mandat à trois ans; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 173.paragraphe S de la Loi des cités et villes du Québec (chapitre 193 S.H.Q.196-1), cette corporation possède le pouvoir d'adopter un règlement pour décréter que la durée des fonctions du inaire et des échevins sera dorénavant de t rois ans; Considérant qu'un tel règlement doit être approuvé par le Lieutenant -gouverneur en conseil; considérant «pie les prochaines élections municipales dans la municipalité de Ville de Rélair auront lieu au mois de novembre 1966: Considérant «pie le conseil de cette corporation juge qu'il est dans l'intérêt des contribuables de se prévaloir des dispositions susmentionnées «\u2022t d'adopter un règlement s'i cet effet; Considérant qu'avis «le présentation du présent règlement a été préalablement donné, soit à la séance de ce conseil tenue le 2ièmc jour de novembre I960; Il est proposé par M.l'échevin: Kmmaumd Dodrigue.Appuyé par M.l'échevin: Homéo Guénette.Il est en conséquence ordonné et statué par règlement de ce conseil portant le numéro B-l4.et ce conseil ordonne et statue comme suit: Titre, article 1 - Le présent règlement portera le titre «le; « Règlement à l'effet «le porter la durée «lu mandat du maire et des échevins de deux-ans à t rois ans » : But, article 2 \u2014- Le présent règlement est adopté «lans le but de porter la durée du mandat du maire et «les échevins de la Ville «le Rélair de «leux ans à trois ans; Définitions, article 3\u2014Les mots «corporation», «municipalité» et «conseil» employés dans le présent règlement ont le sens qui leur est attribué «lans le présent article, à savoir: a) le mot « corporation » désigne la corporation municipale de Ville de Bélair; b) le mot « municipalité » désigne la municipalité de Ville de Bélair; c) le mot « conseil » désigne le conseil municipal «le Ville de Bélair; Mandat trois ans, article 4 \u2014 Ce conseil décrète, par les présentes, que dorénavant la durée du mandai «le son honneur le maire et de Messieurs les échevins est de trois ans (3), et ce à compter des prochaines élections, qui auront lieu au mois de novembre 19(56; Entrée en rigueur, article 5 \u2014 Le présent règlement entrera en vigueur à la première élection générale qui suivra l'approbation dudit règlement par le Lieutenant-gouverneur en conseil; Promulgation, article 6 \u2014 Le présent règlement sera promulgée conformément aux dispositions de la Loi des cités et villes du Québec, chapitre 193 S.R.Q.1964.considering that the Corporation of the Town of Bélair was incorporated as a town by letters patent ami is governed by the provision» of the Quebec Cities and Towns Act.chaptei 193, R.S.Q.1964; considering that the term «»f ollicc of lbs Honour the Mayor and Alessrs the Aldermen i> presently two years, and that it would be bene, ficial to the Corporation, in Order to improve the permanence of municipal administration, to lengthen the term of office to three years; Considering that pursuant to the provisions of section 173.paragraph S of the Quebec Cities and Towns Act (chapter 193.R.S.Q.1964), this corporation has the power to adopt a by-law decreeing that the term of office of the Mayor ami aldermen be, henceforth, three years; Considering that such a by-law must he approved by the Lieutenant-Governor in Council; considering that the next municipal elections in the municipality of the Town of Bélair will take place in the month of November, 1966; Considering that the Council of this corporation deems it to be in the interest of the taxpayers to take advantage cf the aforementioned provisions, and t«> adopt a by-law to this effect : CoNSIDERBfG that a notice of presentation «tf this by-law was given previously, at the Council meeting held on the 2nd day of November, 1965; It is proposed by Air.Alderman Emmanuel Dodrigue.Seconded by Air.Alderman Roméo Guénette.It is therefore ordered ami enacted by by-law «)f this Council bearing number B-l4, and the said Council orders ami enacts as follows: Title, section 1 \u2014This by-law will bear the title of: \"By-law concerning the lengthening of the term of oflice of the mayor and aldermen from two to three years\"; Purpose, section 2\u2014The present by-law is adopted for the purpose of lengtheining the term of office of the Mayor ami Aldermen of the town of Bélair from two to three years; Definitions, section 3 \u2014 The words \"corporation*', \"municipality\" and \"Council\" used in this by-law have the meaning attributed to them in this section, to wit: (a) the word \"corporation\" means the muni cipal corporation of the Town of Bt'dair; (6) The word \"municipality\" means the municipality of the Town of Bélair; (c) the word \"Council*1 means the municipal Council of the Town of Bélair: Mandate three years, section 4\u2014The Council does hereby decree that, henceforth, the mandate of His Honour the Mayor and of Alessrs the Aldermen is one of three years (3).ami buch from ami after the next elections, which will take place in the month of November, 1966; Coming into force, section ô \u2014 This by-law will enter into force at the first general election which will follow the approval of the said bylaw by the Lieutenant-Governor in Council; Promulgation, section 6'-This by-law will he promulgated pursuant to the provisions of the Quebec Cities and Towns Act.chapter 193, R.S.Q., 1964. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 88, 1988, Vol.us, No.18 2347 Adopté à Ville' de Bélair, ce 2Iième jour de février 1066.Le Maire, (iASTON RolilTAILLE.Le Secrétaire-trésorier, .Ikan-Ci.ai'dk grenier.( !opie conforme.I.r Sécréta ire-trêsorier, Je an-Ci.at de Grenier, N.B.Ce règlement est publié conformément à l'article 173, paragraphe S de la loi des eités et villes.Le Sous-ministre des affaires municipales, 14749-0 Je an-Louis DorcKT, eu.Ville de .Murieville Avis est par les présentes donné «pie.par l'arrêté en conseil No 563 du 21) mars 1966, et conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi ilea cités et villes (S.R.Q., 1964.chapitre 193), il o plu au lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver le règlement No 316 du conseil municipal de la ville de Marieville.tel (pic modifié par ledit conseil dans des résolutions adoptées les 2 novembre I960 et 21 février 1966.et de décréter que, à compter de la date de la publication du présent avis, le territoire mentionné audit règlement (d décrit ci-dessous est détaché de la municipalité de la paroisse de Saintc-Marie-de-Mon-noir, comté de Rouvillc.et annexé à la ville de Marieville.( e territoire est le suivant : Un territoire, faisant actuellement partie de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-de-Mounoir.comté de Kouville.comprenant en référence au cadastre officiel de ladite paroisse, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi (pie les chemins, rues, rivières, cours d'eau ou parties d'iceux renfermés dans le périmètre ci-après décrit, à savoir: Parbmt du point d'intersection du prolongement de la ligne sud du lot 271 avec la ligne médiane d'un ruisseau limitant à l'est ledit lot 271; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligue médiane dudit ruisseau >»parant les lots 271 et 272 des lots 145, 146, 14S el 149 jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 149 et 149-A; ledit prolongement; la ligne separative des lots 149 et 149-A et son prolongement à travers le chemin « Rang de l'Église > jusqu'au côté nord dudit chemin; le côté nord dudit chemin en allant vers l'est jusqu'à son intersection avec la ligne separative des lots 147 et 130; partie de ladite ligne separative de lots en allant vers l'est sur une longueur de 1431.95 pieds, soit jusqu'au point d'intersection du prolongement de la limite est de la ville de Marieville à lia vers les lots 150 et 151; ledit prolongement Faisant un angle intérieur de 105° 45' sur une longueur de 732.5 pieds soit jusqu'au point d'intersection de la limite est de la ville de Marie-ville avec la ligne separative des lots 151 et 152; puis suivant les limites actuelles de la ville de Marieville, ladite ligne separative de lots en allant vers l'ouest et faisant un angle intérieur de 74°27' avec le prolongement ci-haut décrit sur une longueur de 1589 pieds; une ligne à travers les lots 161 et 150 et faisant un angle intérieur de 93°56' sur une longueur de 504.62 pieds; une autre ligne faisant un angle intérieur de 237 47' avec la ligne précédente sur une longueur de 305.83 pieds soit jusqu'au point d'intersection du coté non! du Adopted in the Town of Bélair.this 21st day of February.1966.( i ASTON RoHITAII.I.I.Mayor.Jean-Claude Grenier, Secretary'Treasurer, True copy.Jean-Claude Grenier, Secretary-Treas u rer.N.B.This by-law is published in conformity with section 173.paragraph 8 of the Cities and Towns Act.Jean-Louis Doucet, q.c, 14749-0 Deputy Minister of Municipal Affairs.Town of Marieville Notice is hereby given that by Order iu Council No.563 of March 29, 1966, and in conformity with the provisions of section 43, of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 1964, chapter 193), the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to approve by-law No.316 of the Alunicipal Council of the town of Alarieville, such as amended by the said Council in the resolutions adopted on November 2, 1965, and February 21, 1966, and to decree that, from and after the date of the publication of the present notice, the territory mentioned iu the said by-law and hereunder described is detached from the municipality of the parish of Sainte-AIarie-de-Alonnoir, county of Rouville, and annexed to the town of Marieville.This territory is the following: A territory, presently being part of the municipality of the parish of Sainte-Marie-de-Mon-noir, county of Rouville, comprising, in reference to tlic official cadastre of the said parish, lots or parts of lots and their subdivisions, present and future, as well as roads, streets, rivers, water courses or parts of these enclosed in the perimeter hereafter described, to wit: Leaving from the intersection point of the prolongation of the south line of lot 271 with the median line of a stream hounding on the east said lot 271; thence, successively, the following lines and demarcations: the median line of the said stream separating lots 271 and 272 from lots 145, 146, 148 and 149 up to the prolongation of the separative line of lots 149 and 149-A; the said prolongation; the separative line of lots 149 and 149-A and its prolongation across the road \"Rang de l'Église\" up to the north side of the said road; the north side of the said road going east up to its intersection with the separative line of lots 147 and 150; part of the said separative line of lots going to the east on a length of 1431.95 feet, being up to the point of intersection of the prolongation of the cast limit of the town of Alarieville across lots 150 and 151; the said prolongation making an interior angle of 100 4.V on a length of 732.5 feet being up to the point of intersection of the east limit of the town of Alarieville with the separative line of lots 151 and 152; then following the present limits of the town of Marieville, the said separative line of lots going to the west and being an interior angle of 74°27' with the prolongation hereabove described on a length of 1589 feet; a line across lots 151 and 150 and making an interior angle of 93°56' on a length of 504.62 feet; another line being an interior angle of 2370°47' with the preceding line on a length of 305.83 feet being up to the intersection point of the north side of the road \"Rang de l'Église\" 2348 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 98 aeril 1886, 98* année, n° m chemiu « Rang de l'Eglise \u2022> avec le prolonge* ment «le la ligue nord-ouest du loi 149-R; ledit prolongement; la ligue nord-ouest des lots 140-B et 272 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane d'un ruisseau séparant les lots 271 et 272 des lois 270 et 273{ PUIS laissant les limites actuelles de la ville «le Marieville, ladite ligne médiane dudit ruisseau jusqu'au prolongement «le la ligne sud du loi 271; lc town, county of Châtcauguay.in the office of the Secreta ry-T reasi irer.Quebec, April lô.1966, A.Corner.Minister of Agriculture I4S02 and Colonization.Ministère de l'Éducation Department of Education Paroisse de St-Félicien et ville de St-Félicien Demande est faite de fusionner le territoire actuel «les commissions scolaires «le la paroisse et «le la ville «le St-Félicien «lans le comté «le Roi narval et de l'ériger en municipalité scolaire distincte sous le nom «le St-Félicien «lans le comté «le Robcr-val.Québec, le ô avril 1966.14688-16-2-o Le Ministre de l'Education.Paii.(ikimn-Lajoik.140-03 Parish of St-Félicien and town of St-Félieien Application is ma«le to amalgamate the prescnl territory of the school commissions of the parish ami the town of St-Félicien in the county »>l Roberval ami to erect it into a separate Bcnool municipality umler the name «»f St-Félieien iti the county of Roberval.Quebec, April ô.1966.140SN-15-2 Paul Gkkin-Lajoik.Minister of Education.140-61 Ville de Beauceville-Est Beauceville Demande est.faite de fusionner le territoire actuel «les commissions scolaires «le la ville «le Beaueeville-Est dans le comté de Beauce et de Beauceville «lans le comté de Beauce et «le l'ériger en municipalité scolaire distincte sous le nom \u2022 !<¦ Beauceville dans le comté de Beauce.Québec, le 13 avril 1060.Le Ministre de l'Éducation, 14714-16-2-0 Paul Gérin-Lajoik.Town of Beauceville-East Beauceville Application is made to amalgamate the present territory of the school commissions of the town of Bcauccville-East in the county of Beauce.and of Beauceville in the county of Beauce.and to erect it into a separate school municipality under the name of Beauceville in the county of Beauce.Quebec, April 13.1966.Pall Gkiux-Lajoie, 14714-15-2 Minister of Education. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, J900, Vol.93, No.JO 2349 Cap St-Martin Demande est faite (l'annexer le territoire actuel «le la commission scolaire de Cap St-Martin dans le comté «le Laval à la municipalité scolaire catholique de Chomedey- dans le comté de Laval.ce.le 13 avril 1906.l.v Ministre de l'Education, 14715-15-2-0 Paul Gkrin-Lajoib.La Sarre, Paroisse Demande est faite d'annexer le territoire actuel île la commission scliolaire de la paroisse de l.a Sarre dans le comté «l'Abitibi-Ouest a la municipalité scolaire du village de La Sarre dans le même comté et de changer le nom de cette dernière en celui de La Sarre dans le comté d'Abitibi-Ouest.Québec, le 13 avril I960.I.e M inistre de l'Education, i I7I6-15-2-0 Paul Gerin-Lajoib.Si -Atbanase Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la commission scolaire de St-Athanase dans le comté d'ibervilje à la municipalité scolaire de la ville d'Iberville dans le même comté.Québec, le 13 avril 1906.Le Ministre de l'Education.I i7l7-lô-2-o Paul Gewn-Lajoie.Clermont Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté eu conseil No 538, en date du 29 mars 1960.d'annexer le territoire actuel de la commission scolaire de Sic-Agnès, dans le comté «le Charlevoix à la municipalité scolaire «le Clermont, «lans le comté de ( harlevoix.Ce changement prendra effet, pour fins d'élee-tion le 1er juin 1966 et pour toutes autres fins le 1er juillet 1900.\u2022 Québec, le 19 avril 1906.Le Ministre de l'Education.Paul Gkhix-Lajoik.14808*0 65-65 La commission des écoles catholiques de la cité de Jacques-Cartier Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 458 en «late «lu 22 mars 1900, de porter à sept le nombre des commissaires d'écoles pour la commission «les «Voles catholique «le la cité de Jacques-Cartier.Ce changement prend effet à compter de l'élection «le juin 1900.Québec, le 12 avril 1900.Le Ministre de l'Education, 14808-e Pali.Gérin-Lajoik.Commission scolaire régionale Lalonde Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté «n conseil No 456 en «late du 22 mars 1900, d'admettre les commissions scolaires Clermont et St-Étienne-de-Languedoc dams la commission scolaire régionale Lalonde à compter du 1er juillet 1900.Pour fins «le la représentation prévue à l'article 480, les commissions scolaires de Clermont et St-Etienne-de-Languedoc soient ajoutées au groupe «les commissions scolaires de Beaucanton, I bvsmeloizes, Ville de Duparquet, Dupuy, La Heine, Palmarolle, Rapide Danseur, Ste-Anne de Roquemaure, Ste-Hélène, Ste-Jeanne-d'Arc, Cap St-Martin Application is made to.annex the present territory of the school commission of Cap St-Martin in the county of Laval, to the Catholic school municipality of Chomedey in the county of Laval.Quebec, April 13.1966.Pail Gkkin-Lajoik, 1 1715-15-2 Minister of Education.La Sarre, Parish Application is made to annex the present territory of the school commission of the parish of La Sarre in the county of Abitibi-West to the school municipality of the village of La Sarre in the same county and to change the name of the latter to that «>f La Sarre.in the county of Abitibi-West.Quebec, April 13, 1966.Paul Gkkix-Lajoik.14710-15-2 Minister of Education.S t-Atbanase Application is made to annex the present territory of the school commission of St-Athanase in the county of Iberville to the school municipality of the town of Iberville in the same county.Quebec, April 13.1900.Paul Gkuix-Lajoik, 14717-16-2 Minister of Education.Clermont The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council, No.538, «lated March 29, 1900.to annex the present territory of the School Commission of Ste-Agnès, in the county of Charlevoix, to the school municipality of Clermont, in the county of Charlevoix.This change will take effect, for election purposes on June 1st, 1900 and for all other purposes on Julv 1.1900.Quebec, April 19.1900.Pail Gkkix-Lajoik, Minister of Education.14X03 55-65 The catholic school commission of the city of Jacques-Cartier The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.458 dated March 22, 1900, to increase to seven the number of school commissioners for the catholic school commission of the city of Jacques-Cartier.This change takes effect from and after the election of June, 1966.Quebec, April 12.1900.Pail Gkkix-Lajoik, 14S03 Minister of Education.Lalonde regional school board The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.450 dated A larch 22.1900, to admit the Clermont and St-Étienne-de-Languedoc school commissions in the Lalonde regional school board from and after the 1st of July, 1960.For representation purposes provided for in section 480, the Clermont and St-Êtienne-de-Languedoc school commissions be added to the group of school commissions of Beaucanton.Desmeloises, Ville de Duparquet, Dupuy, La Reine, Palmarolle, Rapide Danseur, Ste-Anne de Roquemaure, Ste-Hélène, Ste-Jeanne-d'Arc. 2380 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 28 avril 1960, 9X' année, n° 10 St-Laurcut-dc-Palmarolle, St-Mathias, Val Paradis, Val St-Clilies, Villehois, Tasehereau, Colom-hourg, Ste-(îennaine, St-Janvier, Laferté <-t Authier.Québec, le 13 avril I960.Le M inistre île V Education, Paul Gbrin-Lajoib, 14803-e- 1945-01 La commission des écoles catholiques de Montréal Il a plu-au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 538, en date du 29 mars 1900, de détacher de la municipalité scolaire de St-Léo-nard-de-Port-Maurice, dans le comté de Bourget.le lot No 370 du cadastre officiel de la paroisse de Sault-au-Récollet pour l'annexer, pour les catholiques seulement, au territoire sous la juridiction de la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal.Ce changement prendra effet, pour fins d'élection le 1er juin 1900 et pour toutes autres fins le 1er juillet 1900.Québec, le 19 avril 1900.Le Ministre de l'Education, Paul Guëbix-Lajoie.14803-0 246-65 Rosemère Cat h.11 a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil numéro 457, en date du 22 mars 1966, «le détacher «le la municipalité scolaire de Bois-des-Fillion, «lans le comté de Terrebonne, le territoire de la ville «le Lorraine, tel qu'érigé par la Loi 8-0 Elisabeth IL chapitre 102.pour l'annexer, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire catholique «le Rosemère, «lans le comté de Terrchonne.Ce changement prendra effet pour fins d'élection le 1er juin 1900, et jxnir toutes autres fins le 1er juillet 1906.Québec, le 15 avril 1900.Le Ministre de l'Éducation, Paul Gkrix-Lajoik.14S03-o \u2022 107-05 St-Laurent-de-PalmarolIe, St-Mathias, Val Paradis, Val St-Gilles, Villehois, Tasehereau, Colom-hourg.Ste-Gcrmaine, St-Janvier, Laferté and Authier.Quebec, April 13.1900.Pail Gkhix-Lajoii:.Minister of Education.14S03 1945-61 The catholic school commission of Montreal The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.538, «latc«l March 29, 1966, to detach from the school municipality of St-Léonard-de-Port-Maurice, in the county of Bourget, lot No.370 of the official cadaster of the parish of Sault-au-Récollet to annex it.for the Catholics only.t«> the territory under the jurisdiction of the catholic school commission of Montreal.This change will take effect, for election pur-poses, on June 1.1900.and for all other purposes, on July 1.1900.Quebec, April 19.1900.Paul Gebin-Lajoie, Minister of Educution.14803 246-05 Rosemère Cat h.The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council number 457, dated March 22, 1966, to detach from the school municipality of Bois-des-Filion, in the county «>f Terrebonne, the territory of the town of Lorraine, such as erected by the Act 8-9 Eliaxbeth II, chapter 162, to annex it, for the Catholics only, to the Catholic School Municipality «>f Rosemère.in tin-county of Terrebonne.This change will take effect for election purposes on June 1.1900.and for all other purposes on July 1, 1900.Quebec, April 15.1900.Pail Gkkix-Lajoik.1/initier of Education.14803 167-05 St-François-du-Lac 11 a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 458 en date du 22 mars I960, de détacher de la municipalité scolaire de St-Michel No 2 «lans le comté d'Yamaska les lots 283 et 284 «lu catlastre officiel de la paroisse «le St-Alichel d'Yamaska, pour les annexer à la municipalité scolaire de St-François-du-Lac dans le comté d'Yamaska.Ce changement preml effet pour fins d'élection le 1er juin et pour toutes autres fins le 1er juillet 1900.Québec, le 12 avril 1900.Le Ministre de l'Éducation.Paul Gbrin-Lajoib.14803-o 882-04 St-Fran«5ois-du-Lac The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.458 dated March 22, 1900.to detach from the school municipality of St-Michel No.2 in the county of Yamaska lots 283 and 284 of the official cadaster of the parish of St-Michel d'Yamaska, to annex them to the school municipality of St-François-du-Lac in the county «>f Yamaska.This change takes effect for election purposes on the 1st of June and for all other purposes on on the July 1, 1960.Quebec, April 12.1900.Pail Gkhix-Lajoik, Minister of Education.14803 882-64 Ste-Monique Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 538, en date du 29 mars I960, de détacher «le la municipalité scolaire de Grand-St-Esprit, dans le comté «le Nicolet, les lots 31 à 70 inclusivement et 101 à 142 inclusivement du cadastre officiel de la paroisse «le Ste-AIoniquc gour les annexer à la municipalité scolaire de te-Monique, dans le comté «le Nicolet.Ste-Monique The Lieutenant-Governor has l>een pleased, by Order in Council No.538, dated March 29, I960, to detach from the school municipality of Grand-St-Esprit, in the county of Nicolet, lots 31 to 70 inclusively ami 101 to 142 inclusively in the official cadaster of the parish of Ste-Monique, in order to annex them to the school municipality of Ste-Monique.in the county of Nicolet. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.April 23, J9GG, Vol.98, No.16 2351 ( V changement prendra effet, pour fins d'élection le 1er juin 1900 et pour toutes autres fins le 1er juillet 1900.Québec, le 19 avril 1966, Le Ministre de l'Éducation, Paul Gkkix-Lajoik.14803-0 262-65 Chomedey Cath.Demande est faite de détacher de lu municipalité scolaire catholique de Chomedey, dans le comté de Laval, les lots 215, 220, 226, 227, 239, P-241, 243, P-244, P-245, P-246, P-247, 248, 249, 2ô2 et P-250 du cadastre officiel de la paroisse «le St-Martin pour les annexer, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire de la ville de Laval-des-Rapidcs, dans le comté de Laval.Quél>cc, le 15 avril 1960.Le Ministre de VEducation, Paul Gkrin-Lajoib.llSOt-lG-2-o 51-05 Tins change will take effect, for election purposes, on June 1.1900.and for all other purposes on July 1, 1900.Quebec, April 19.1966.Paul Gbmn-Lajoie, Minister of I'd neat ion.14803 262-65 Chomedey Cath.Application is made to detach from the Catholic school municipality of Chomedev, in the county of Laval, lots 215, 220, 220, 227, 239, P-241, 243.P-244, P-245, P-246, P-247, 248, 249, 252, and P-250 in the official cadaster of the parish of St-Martin, to annex them, for Catholics only, to the school municipality of the town of Laval-des-Rapides, in the county of Laval.Quebec, April 15, 1900.Pall Gkkix-Lajoik, Minister of Education.14804-10-2 51-05 burn ha in-Ouest Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la commission scolaire de Farnham -Ouest, dans le comté de Missisquoi, à la muni-cipalité scolaire de la ville de Farnham, même comté et de clianger le nom de cette dernière en celui de « Farnham », dans le comté de Missisquoi.Québec, le 19 avril 1900.Le Ministre de l'Éducation, I1S05-10-2-o Paul Gkkix-Lajoik.Farnham-West Application is made to annex the present territory of the school commission of Farnham-West, in the county of Missisquoi, to the school municipality of the town of Farnham, same county, and to change the name of the latter to that of \"Farnham\", in the county of Missisquoi.Quebec, April 19, 1900.Paul Gkkix-Lajoik, 14805-10-2 M in ister of Education.Lotbinière Paroisse Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la commission scolaire de la paroisse de Lotbinière, dans le comté de Lotbinière, à la municipalité scolaire du village de Lotbinière dans le même comté.Québec, le 15 avril 1900.Le Ministre de l'Education, 11S0G-10-2-o Paul Gkrix-Lajoie.Lotbinière Parish Application is made to annex the present territory of the school commission of the parish of Lotbinière, in the county of Lotbinière, to the school municipality of the village of Lotbinière in the same county.Quebec, April 15, 1900.Paul Gkkix-Lajoik, 14800-10-2 M in ister of Education.St-Cyriac Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la commission scolaire de St-Cyriac, dans le comté de Jonquière-Kénoganii, à la municipalité scolaire de la cité de Jonquière, dans le comté de Jonquière-Kénogami.Québec, le 15 avril 1906.Ministre de VÉducation.14807-16-2-o Paul Gkrix-Lajoik.St-Cyriac Application is made to annex the present territory of the school commission of St-Cyriac, in the county of Jonquière-Kénogami, to the school municipality of the city of Jonquière, in the county of Jonquière-Kénogami.Quebec, April 15, 1900.Paul Gkrix-Lajoik, 14807-10-2 Minister of Education.Ministère des Finances Department of Finance Assurances Insurance Home Fire and Marine Insurance Company of California Avis de changement de nom Avis est donné, par les présentes, que « Home l'ire and Marine Insurance Company of California », dont le siège social est situé à San Francisco.Californie, États-Unis d'Amérique, et enregistrée dans la province de Quél)ec sous le numéro 337, a changé son nom en celui de « Fireman's bund Insurance Company ».Home Fire and Marine Insurance Company of California Notice of change of name Notice is hereby given that \"Home Fire ami Marine Insurance Company of California\", whose head office is situated in San Francisco, California, United States of America, and registered in the Province of Quebec umler number 337, has changed its name to \"Fireman's Fund Insurance Company\". 2352 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 88 avril Ï9Û6, 88* année, »° w Donné nu bureau du Service des assurance Ministère «les finances, le 21 janvier 1000.Pour le Ministre des finances de la I'roriiice.I.e Surintendiiat des assurances, I 1089-15-2-0 Roger-A.Camabaire, Given at the office of the Insurance Branch, Depart ment of Finance, the 24 of January 106(1, For the Minister of Finance of the I'roriiice, Ro< ; br- A.( 'am a u ai u i :.14689-15-2-0 Superintendent of Insurance.Ministère de l'Industrie <*t du Commerce Department of Industry ami Commerce I.ni sur les pêcheries Règlement de pêche du Québec Avis «le pêche aux coques Vu la décision du Ministre «le la Santé Nationale et «lu Bien-Être Social à l'effet que les coques «les régions coquillères situées le long «les côtes et des eaux: N-6.1: Région s'étendant «le l'ointe aux Outardes ouest à Grosse l'ointe sont toxiques à un point «iui les rend dangereuses pour la consommation ù l'état cru.À ces causes et conformément à l'article ô, paragraphe 1, «lu règlement «le pêche du Québec, par les présentes, il plaît au Alinistrc «le fermer lesdites régions à la pèche et «l'interdire à «pli-conque «le pêcher, de prendre ou «l'avoir en sa possession des coques provenant desdites régions.La présente interdiction ne s'applique pas cependant aux producteurs licenciés (Arrêté en conseil Québec, 1963-770) pour la mise en conserve seulement.Québec, le 31 mars 1900.Le M inistre de l'Industrie et Commerce par intérim, 14751-0 Kmc Kikhans.Loi sur les pêcheries Règlement de pêche du Québec Avis «le pèche aux coques Vu la décision «lu Alinistrc «le la Santé Nationale et «lu Bien-Etre Social à l'effet que les coques des régions coquillères Bituées le long a degree unsafe for use as a raw food.Therefore, pursuant t<> section ô, paragraph 1.of the Quebec Fishery regulations, the Minister hereby closes the sai«l areas and forbids anybody whatsoever to fish, take or to have in his possession, clams from the said areas.The present interdiction does not apply however to licensed producers.(Qucliec Order in Council, 1963-779), for canning purposes only.Quebec, March 31, 1000.Eric Kibrans, Minister of Industry 147Ô1 and Commerce Pro tempore.Fisheries Act Quebec Fishery Regulation Notice of Clam Fishing In view of the decision rendered by the Minister of National Health and Welfare t«> the effect that clams in shellfish areas located along the shores ami waters: N-4.2 Region extending from the bridge of the Blanche River-bridge of the Colombier River; N-4.3 Region extending from the bridge of the Colombier River-Pointe Bersimis (Bane des Canadiens) arc no longer toxic to a degree unsafe for use ;t-B raw food.Therefore, pursuant to section 6, paragraph I.of the Quebec Fishery regulations, the Minister hereby opens the said areas and permits anybody whatsoever to fish, take or to have in his possession, clams from the said areas.Québec, April 5, 1900.Ehic Ki khans, Minister of Industry 147ÔI and Commerce pro tempore.Fisheries Act Quebec Fishery Regulation Notice of Clam Fishing In view of the decision ren«lere«l by the Minister «if National Health and Welfare to the effect QUI MIT, OFFICIAL GAZETTE, April 23, 1900, Vol.US, Xo.10 2353 région! coquilièrcs situées le long des eûtes et ,lcs eaux: N'-ll.l l'étendant de l'ointe aux Anglais à l'ointe Sproulc ne sont plus toxique à un point qui les rend dangereuses pour la consommation àl'êtat cru.\\ ces causes et conformément à l'article ô, paragraphe 1, du règlement de pèche du Québec, par les présentes, il plaît au Ni inistre d'ouvrir lesdites régions à la pêche et de permettre à quiconque de pêcher, de prendre ou d'avoir en sa possession des coques provenant «lesdites régions.Québec, le 13 avril 1966.l.c Ministre de T Industrie et Commerce, i i7ôl-o Gbraro Lévesque.Ministère du Travail Avis de modification Métal en feuilles Montréal L'honorable Carrier Fortin, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément dispositions de la Loi des décrets de convention collective (S.H.Q.1964, chapitre 143).qu'il a l'intention de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil la modification suivante au décret numéro S27 du Il août 1958 et amendements, relatif à l'industrie de la fabrication «les produits de la tôle métal en feuilles) dans l'Ile «le Montréal et un rayon de vingt -cinq (25) milles de ses limites; Les paragraphes « l> 1 et «c» «le l'article III -iront remplaces par les suivantes: h) Sujet aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe « <\u2022 » «lu présent article, le décret ne s'applique pas à la fabrication «les cuisinières, ni à la construction «le navires d'au-delà de 25 pieds de longueur, d'avions ou à la fabrication ilis produits suivants: cannettes en métal et ustensiles, réfrigérateurs et humidificateurs élec-trûpies pour usage «loniestupie.radiateurs élec-iriipies, chaufferettes électriques, lampes électriques, appareils et accessoires électriques, cylindres «le métal destinés à l'entreposage et à la distribution «lu gas propane.r) Nonobstant les dispositions précédentes, lorsqu'un établissement s'occupe de la fabrication d'articles ou «le produits dont quelques-uns sont exemptés «le l'application «lu présent décret.If décret s'applique aux employés et à la partie de leur travail qui n'est pas exemptée, Cependant si.au moment de l'exécution du travail, il est impossible «le faire la distinction entre le travail exempté et le travail non exempté.!<\u2022 décret s'applique aux salariés dont le travail participe, nccasiouncllcmcnt ou r«:gulièrement, à la fabrication «l'un ou «le plusieurs articles ou produits assujettis au décret.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions «pii y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement, b'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la «late «le sa publication «lans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la «laie de publication «le cet avis «lans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre «lu Travail rece- that clams in shellfish ar«-a located along the shores and waters: N-ll.l extending from Pointe aux Anglais to Pointe Sproule are no longer toxi«: t«> a degree unsafe for use as a raw food.Therefore, pursuant to Section ô.paragraph I of the Quebec Fishery regulations, the Minister opens the said areas, ami permits anybody whosoever to fish, take or have in his possession, «dams from the said areas.Quebec, April 13.1966, GJsbaru Levés tjt I- 14751 Minister of Industry and Commerce.Department of Labour Notice of amendment Sheet- metal fabricating iml ustri/ - .1/out real Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q.1964, chapter 143), the Honourable Carrier Fortin, Minister of I^alxmr, hereby gives notice that he intends .submitting the following amendment to «lecree number 827 of August 14, 1958 and amendments (Sheet-metal products fabricating industry in the Island of Montreal and a 20-mile radius from its limits) to the consideration and decision «>f the Lieutenant-Governor in Council: Subsections \"//' and \"c\" of section III will l>e replaced by the following: \"(b) Subject to the provisions of the second paragraph, subsection \"c\" of this section, the «lecree does not cover the manufacturing of stoves, the construction of boats over 25 feel long, aircraft or the following products: tin cans and utensils; electric home refrigerators and humidifiers; electric heaters, radiators, lamps, appliances and accessories; metal cylinders for propane gas storage or distribution.(c) Notwithstanding the foregoing provisions, when a firm manufactures some items or products which are exempt from the present decree's coverage, the «lecree shall cover employees and that part of their work which is not exempt.When, in a working situation, it is impossible t«> make a clear-cut distinction between exempt and non-exempt work, the «lecree shall cover employees whose work occasionally or regularly participates in the manufacture or one or more items or products subject to the decree.\" Publication of this notice does not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can l>c made binding only by an Order in Council, which comes into force on the «late of its publication iu the Quebec Official Gazette.During the thirty «lays following publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Alinister of Labour will consider 2354 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 23 avril 1966, 98' année, n° Hi vra les objections, en double copie si possible, que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre du Travail, GÉRARD Trkmblay.Ministère du Travail, Québec, le 23 avril 1900.14736-o Avis de modification Matériaux de construction \u2014 Province L'honorable Carrier Fortin, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Ix)i des décrets de convention collective (S.R.Q.19(54, chapitre 143), que les Métallurgistes Unis d'Amérique lui ont présenté une requête ù l'effet d'être acceptés comme partie contractante au décret numéro 2203 du 6 décembre I960 et amendements, relatif à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec section IV (Blocs de ciment), section V (Tuyaux de ciment ou de béton) et section VI (Dalles de béton).La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrête en conseil ne peut entrer en vugueur avant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections, en double copie si possible, que les intéressés jxnirront désirer formuler.Le sous-ministre du Travail, G Kit AH I) TliKMBLAY.Ministère du Travail, Quélwc, le 23 avril 196(5.14730-u Avis de prélèvement L'honorable Carrier Fortin, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité paritaire de l'industrie de la construction de Drummondville.établi en exécution du décret numéro 988 du 2 octobre 195S.a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro (534 du 5 avril 19(56, section « C ».le tout d'accord avec les dispositions de la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q.19(54, chapitre 143).à prélever des cotisations «les employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant les conditions ci-après décrites: 1.( ofisation La période de cotisation s'étend du 1er mai 19(5(5 au 30 avril 1907; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 988 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 1-j de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.6) Les artisans régis par ledit décret numéro 988 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ' j de 1% du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré.c) I^es salariés régis par ledit décret numéro 088 et amendements doiver au Comité paritaire une somme équivalente à 1 \u2022_, de 1% de leur rémunération.objections which interested parties may wish to make; objections should be submitted in duplicate if possible.(i h KAKI) TltKMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Québec, April 23, 1906.14730,, Notice of amendment Building Materials \u2014 Province Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q.19(54, chapter 143), the Honourable Carrier Fortin, Minister of Labour, hereby gives notice that the United Steel Workers of America have petitioned him to Ik- accepted as contracting party to decree number 2203 of Deceml>er 0, 19(50 and amendments (Building Materials industry in the Province of Québec), for section IV (Concrete or cement blocks), section V (Concrete or cement pipes) and section VI (Concrete or cement slabs).Publication of this notice does not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can l>e made binding only by an Order in Council, which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider objections which interested parties may wish to make; objections should be submitted in duplicate if possible.GÉRARD Thkmblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Québec, April 23, 19(50.14736m Notice of levy Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q.1904.chapter 143).the Honourable Carrier Fortin.Minister of Labour, hereby gives notice that the Building Trades Joint Committee of Drummondville (established in pursuance of decree number 988 of October 2, 1958) has been authorized to levy \u2022lues on the professional employers, artisans and employees subject to the said decree, according to the conditions mentioned below.A by-law.approved by Order in Council numlier 034 of April 5.1900.section \"C\".authorizes such levy.1.Dues The contribution period extends from May I 1900 to April 30.19(57.It is carried out as follow-: (a) Professional employers governed by said decree number 988 and amendments shall pay the Parity Committee an amount equivalent to '2 °f 1% of their payroll for the employee-subject to the said decree.(6) Artisans covered by said decree number 988 and amendments shall turn over to the Parity Committee an amount equivalent to \\'i of 1% of the salary laid down in the decree for the lowest-paid journeyman.(c) Employees governed by said decree number 988 and amendments shall turn over to the Parity Committee an amount equivalent to 1 _» of 1% of their salary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 1966, Vol.OS, So.16 2355 2.Mode de perception Kn vue «le faciliter la (lerseption de 081 cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 10 du mois suivant la date d'expiration île la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Ia' Comité a le pouvoir «l'exiger Passermentation dudit rapport chaque fois qu il le juge à propos.Ia' prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise eu demeure au préalable.3./{apport financier D'accord avec la Loi «les décrets «le Convention Collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel «le ses opérations au Ministre «lu Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars.30 juin.30 septembre et 31 décembre de chaque année.Ci-annexé.un état «les recettes et des débounés prévus «lu Comité paritaire «le l'Industrie d la Construction «le Drummondville.pour la période comprise entre le 1er mai 1000 et le 30 avril 1007.4.Disposition spéciale Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux employeurs professionnels \u2022 I aux salariés assujettis au décret numéro 1288 «lu 2 juillet 1904, relatif à la construction des lignes «le transmission, et à l'arrêté en conseil numéro 2284 (C) «lu 22 novembre 1901 et ses amendements, relatifs à l'Industrie de l'acier de bI ructure, dont la mise à exécution a été confiée au Comité paritaire susmentionné.Lk Comité paritaibi on l'Indurtrib ni: la construction dr Drummoxi)villk Etat «les recettes et «les déboursés probables pour la période comprise entre le 1er mai 1900 et le 30 avril 1907.Recettes: Cotisations patronales.S 40.100.00 Cotisations ouvrières.47.445.00 Cotisations artisanales.3,125.00 Honoraires d'examen.900.00 Int.«le banque.2,000.00 Impôt fédéral.2.800.00 Impôt provincial.1.500.00 Assurance-groupe.1,200.00 Fonds de pension.1,000.00 Rentes du Québec.792.00 $100,922^00 Déboursés: Salaire du secrétaire.S 10,000.00 Salaire du personnel.15,950.00 Salaire des inspecteurs.28,325.00 Frais d'inspection.12.000.00 I I«>n : Bureau d'examinateurs.2,300.00 2.Collection method To facilitate the collection «>f such dues, the Parity Committee supplies professional employers with report forms on which all the information requested by the said Parity Committee must Ir> given.Every month, the professional employer must complete, sigh ami forward his report to the Parity Committee.The professional employer must forward his monthly report to the Parity Committee on or before the 10th of the month following the expiry «late of the period for which it is required.The professional employer's «lues together with those of his employees must accompany said report.The Committee has the authority to request an attestation of the said report whenever it shall deem it advisable.The levy imposed by this by-law is payable monthly by the professional employer, the artisan ami the employee, without formal notice beforehand.3.Financial report lu compliance with the Collective Agreement Decrees Act.the Parity Committee must submit a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour on the following set dates: March 31.June 30.September 30 ami December 31 of each year.A statement of estimated receipts and disbursements of the Building Trades Joint Committee of Drummondville for the May 1.1900 to April 30.1907 period is given below, 4.Special provision The provisions of the present by-law also cover professional employers and employees subject to decree number 1288 of July 2.1904 (Construction of Transmission Lines) and to Order in Council number 2284 (C) of November 22.1901 and amendments (Structural Steel Industry), whose application has been entrusted to the abovementioned Parity Committee.Tub Builoing Trades Joint Committer of Drummondville Statement of estimated receipts and disgursc-ments for the May 1.1966 to April 30, 1907 pcrio«L Receipts: Employers'dues.t 40.100.00 Employees' dues.47,445.00 Artisans'«lues.3,125.00 Examination fees.900.00 Bank interest.2,000.00 Federal tax.2.800.00 Provincial tax.1.500.00 Group insurance.1.200 00 Pension fund.1,000.00 Québec Pension Plan.792.00 S100.922.00 Disboursciiwnts: Secretary's salarv.?10,000.00 Staff's salary.15.950.00 Inspectors' salaries.28.325.00 Inspection expenses.12.000.00 Fees : Board of Examiners.2.300 00 2356 GAZETTE OFFICIELLE DE QU 1)11 El', 23 avril HHiti, ON' année, n° Ki Frais: Bureau d'examinateurs.$300.00 Loyer et taxes.826.00 Eclairage, ch.entretien.1.250.00 Frais judiciaires.0.000.00 Frais de vérification .300.00 Impression, papeterie, ace.hur.1,400.00 Poste, Téléphone, télégramme.1,250.00 lut.échange, agios.450.00 Abonnement, publicité.000.00 Jetons de présence.S00.00 Frais «le déplacement s.3,000.00 Frais «le «lélégat ion.1,320.00 Frais d'affiliation.4SI).00 Cours «le formation.1,500.00 Assuruncc-clmmagc.550.00 Assurance-grou|>e.2.520.00 Assurances générales.1 ,S00.00 Fonds de pension.2,350.00 Impôt fédéral.2.800.00 Impôt provincial.1.500.00 Rentes «lu Québec.1,584.00 §102,854.00 Excédent «les recettes sur les the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q.1964, chapter 143).the Honourable Carrier Fortin.Minister of Labour, hereby gives notice that the Fur Industry Parity Committee, wholesale section of Montreal (established in pursuance of decree number 524 of Mav 11, 1955.) has been authorized to levy dues on the professional employers, artisans and employees subject to the said «lecree.according to the conditions mentioned below, A by-law.approved by Order in Council number 034 of April 5, 1900.section \"B\", authorises such levy.1.Dues The contribution period extends from May I.1900 to April 30.1907.It is carried out as follow - (a) Professional employers governed by said «lecree number 524 ami amendments shall pay the Parity Committee an amount equivalent to } o of \\% of their payroll for the employees subject to the said decree (fixed salaries, perceli tages.allowances, commissions or bonuses paid i.(b) Artisans covered by said decree number 524 and amendments shall turn over to the Parity Committee an amount equivalent t«» 1 of 1% of the salary laid down in the said «lecree for the lowest-paid journeyman (or the average wage laid down by the Committee).(c) Employees governed by said «lecree number 524 and amendments must turn over to the Parity Committee an amount equivalent t«» 1 ¦_\u2022 «)f 1% of their fixed salaries, commissions, bonuses and allowances.2.Collect ion inetlunl To facilitate the collection of such «lues, the Parity Committee supplies professional cm QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April $8, 1900, Vol.OS, Xo.10 2357 des employeurs professionnels, des formules (le rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés pur ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir a u Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit transmettre soil rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le lOième jour du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel cl de celles de ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque lois qu'il le juge i'i propos.L'employeur professionnel doit percevoir, à la lin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ses cotisations ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq ô) jours lui sera donné pour remplir ses obliga-lions envers le Comité paritaire.3.Hup port financier Conformément à la Loi des décrets de Convention Collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars.3D juin.30 septembre et 31 décembre de chaque année.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire de l'Industrie de la Fourrure, section du Gros, de Montréal, pour la période comprise entre le 1er mai 1000 et le 30 avril 1007.bl\".Co.mité p ABIT AIRS DE I.TnDI'STHIK ni: la FouRBURB, Section nr Gros ni; Montréal 1010 est.rue Ste-Catherine.suite 401-402.Montréal, P.Q.État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er mai 1900 «\u2022t le 30 avril 1907.Recettes: Cotisations patronales .$31,000.00 Cotisations ouvrières.31,000.00 Cotisations artisanales .3,000.00 Pénalités et amendes.5.000.00 Intérêt de banque.00.00 Impôt fédéral.1.710.00 Impôt provincial.949.00 Assurance-chômage.335.00 Rentes du Québec.501.00 $73,621.00 Déboursée: Salaire du secrétaire.$ 5,720.00 Salaire du personnel.11.232 00 Salaire des inspecteurs .19,084.00 Frais d'inspection.3.940.00 Loyer et taxes.2.900.00 Kclairage.ch.entretien .250.00 Frais judiciaires.9,000.00 ployers with report forms on which all the information requested by the said Parity Committee must be given.Every month, the professional employer must complete, sign and forward his report to the Parity Committee.The professional employer must forward his monthly report to the Parity Committee on or before the 10th of the month following the expiry date of the period for which it is required.The professional employer's dues together with those of his employees must accompany the said report.The Committee has the authority to request an attestation of the said report whenever it shall deem it advisable.At the end of each week and on the Committee's behalf, the professional employer must collect, by means of a check-off.the levy imposed on his employees.The levy imposed by this by-law is payable monthly by the professional employer, the artisan and the employee, without formal notice beforehand.Should a professional employer or an artisan refuse to pay his dues or supply necessary information, he will be given five (5) days' notice so that he may fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report In compliance with the Collective Agreement Decrees Act, the Parity Committee must submit a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour on the following set dates: March 31, June 30.September 30 and December 31 of each year.A statement of estimated receipts and disbursements of the Fur Industry Parity Committee, wholesale section of Montreal, for the May 1.1900 to April 30.1907 period is given below.The Fur Industry Parity Committee wholesale section ok Montreal Suite 401-402.1010 St.Catherine Street Fast.Montreal.P.Q.Statement of estimated receipts and disbursements for the May 1.1900 to April 30.1907 period.Receipts: Employers' dues.$31,000.00 Employees' dues.31,000.00 Artisans' dues.3.000.00 Penalties and fines.5,000.00 Hank interest.00.00 Federal tax.1.710.00 Provincial tax.949.(X) Unemployment Insurance .335.00 Québec Pension Plan .501.00 $73,621.00 Disbursements: Secretary's salary $ 6,720.00 Staff's salary.11.232 00 Inspectors'salaries .19.084.00 Inspection expenses.3.940.00 Rent and taxes.2,900.00 Lights, heat, maintenance .250.00 Legal fées.9.900 00 2358 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 23 avril 1966, H8' année, n\" 16 Frais de vérification.$ 1,000.00 Impression, pupeterie, acc.bureau 3,000.00 Poste, téléphone, télégramme 1,100.00 Abonnement et publicité.50.00 Jetons de présence.I ,S00.00 Frais de déplacements .7.200 (H) Frais de délégation.300.00 Assurance-chômage.070.00 Assurance-caution.10.00 Assurances générales.00.00 Rentes du Québec.1,122.00 Impôt fédéral.1.710.00 Impôt provincial .949.00 «72,003.00 Excédent des recettes sur les déboursés.I 1,01 S.00 Auditor's fees.SI .000.011 Printing, stationery, office equipment.3,000.00 Postage, telephone, telegrams.1,100.00 Subscription and advertising.50.00 Attendance tokens.1,800,00 Travelling expenses.7,200,00 Delegation expenses.300(H) Unemployment Insurance.070.00 Fidelity bond.10.00 (iencrul insurance.00.00 Québec Pension Plan.1,122.00 Federal tax.1,710 00 Provincial tax.949.00 $72,003.00 Surplus .$ 1.618.00 Le sous-ministre du Travail, Gerard Tuk.mbi.av.Ministère du Travail, Québec, le 23 avril 1966.14736*0 Gerard Tremblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Québec.April 23.1960.147.Hi- Nominations Appointments Présidents d'élection Il a plû à son Honneur le lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil exécutif, par commission sous le grand sceau, de faire, pour remplir la charge de présidents d'élection, les nominations suivantes: Returniiig-Odicers His Honour the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the executive Council to appoint by commission under the Great Seal, to fill the office of returning -officers, the persons whose name follows : District électoral Electoral district\tNom, prénom Name, Christian name\tProfession ou occupation Profession or calling\tDomicile Domicile Labelle.Matapédia.Montréal-Mercier.Rouville.Terrebonne.\tRicard, Joachim (1).BÔrubé, Lionel (2).Ouimet, Gérard (3).Ouimet, Gérard (4).Latinise, Thomas (5).Mathieu.Guy (fi).\tEntrepreneur \u2014 Contractor.Rentier \u2014 Retired.Représentant \u2014 Agent.Représentant \u2014 Agent.Pomicultour \u2014 Orchardist.Avocat \u2014 Advocate.\tVal Barrette.Amqui.Montréal.Montréal.Mont gt-Hilairc.Saint-Jérôme.(1) En remplacement de monsieur Benoît Godard, démissionnaire.\u2014 In place of Mr.Benoît Godard, reaignei (2) En remplacement de monsieur Joseph-Antoine Beaulieu, démissionnaire.\u2014 In place of Mr.Joseph-Antoine Beaulieu.resigner.(3) En remplacement de monsieur Rodolphe Masson.démissionnaire.\u2014 In place of Mr.Rodolphe Masson, résigner.(4) En remplacement de monsieur Rodolphe Masson, démissionnaire.\u2014 In place of Mr.Rodolphe Masson, resigner.(5) En remplacement de monsieur Jacques Marcoux.démissionnaire.\u2014 In place of Mr.Jacques Manou\\.resigner.(6) En remplacement de monsieur Pierre Rousseau, démissionnaire.- In place of Mr.Pierre Rousseau, resigner.Québec, le 20 avril 1906.Le Président général des élections, 14737-0 François Drouin, c.r.Quebec, April 20, 1966.François Drouin, q.c., 14737-o Chief Returning-Officcr.Proclamations Proclamations HUGUES LAPOINTE Canada.Province de Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth.Défenseur de la foi.HUGUES LAPOINTE Canada.Province of Quebec.|L.8,1 ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Queen, Defender of the Faith. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 1966, Vol.93, So.Id 2351) À tous ceux qui les présentes verront ou qu'ieel-les pourront concerner, Salit.Proclamation ATTENDU que c'est Notre désir et Notre bon plaisir de rencontrer aussitôt que possible le peuple de la province de Québec et d'obtenir son avis exprimé en parlement; À CES causes, sur l'avis du Conseil exécutif de la province de Québec, Nous convoquons par les présentes une nouvelle législature de la Province pour le vingt juin prochain et mandons et ordonnons à ses membres de s'assembler à cette date au palais législatif, en la cité de Québec.Kn foi de QUOI, Nous uvons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de la province de Québec.TEMOIN: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues LAPOINTE» ci».C.B., lieutenant-gouverneur de ladite Province.Donné en Notre hôtel du gouvernement, à Québec, le dix-huit avril, l'an de grâce mil neuf cent soixante-six et de Notre règne le quinzième.Par ordre.Le Secrétaire Oêtoeié, de la Chancellerie.!4siô-l()-8-o Jean Sénégal.To ull to whom these presents shall come or whom the same many concern, GREETING, Proclamation WHEREAS We are desirous and have decided to meet as soon as possible the People of the Province of Quebec and to have their advice, expressed in Parliament ; THEREFORE, by and with the advice of the Executive Council of the Province of Quebec, We do hereby convene a new Legislature of the Province for the twentieth day of June next, and do command and order the members thereof to meet on such date at the Parliament Buildings, in the city of Quebec.In TESTIMONY wmkkkof.We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of the Province of Quebec- to be hereunto affiled.WITNESS.' Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable Hugues LAPOINTE, P.C., q.c.Lieutenant-Governor of the said Province.At Our Government House, at Quebec, this eighteenth day of April, in the year of Our Iiord one thousand nine hundred and sixty-six and the fifteenth year of Our Reign.By command.Jean Senegal, Clerk Associate of the Croien 14N15-16-S-o in Chancery, Quebec.( 'anada.Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défendeur «le la foi.À tous ceux qui les présentes verront ou \u2022 lu'icelles pourront concerner.Saut.Proclamation ATTENDU «|Ue c'est Notre désir et Notre lion plaisir de rencontrer aussitôt que possible le peuple de la province de Québec et d'obtenir son avis exprimé en parlement: A ces causes, Nous faisons connaître par les présentes que, sur l'avis «lu Conseil exécutif de la province de Québec, Nous Nous avons ce jour donné des ordres |>our l'émission de brefs d'élec-t ion en due forme afin de constituer une nouvelle Assemblée législative de ladite Province, lesquels brefs d'élection seront tous datés du dix-huit avril 1966 et devront être rapportés avant le dix juillet 1966, la présentation des candidats à l'élection devant avoir lieu et se faire le vingt-deux mai 1966 dans tous les districts électoraux; et le scrutin, quand il sera nécessaire d'en tenir un, devra avoir lieu le cinq juin I960 dans tous les districts électoraux.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de la province «le Québec.TÉMOIN: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, O.P.c.b., lieutenant-gouverneur «le ladite Province.Donné en Notre hôtel du gouvernement, à Québec, le dix-huit avril, l'an de grâce mil (.'anada.Province of HUGUES LAPOINTE Quebec.[L.S.) ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas.Queen.Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern.Greeting.Proclamation WHEREAS We are desirous and have decided to meet as soon as possible the People of the Province of Quebec, and to have their advice, expressed in Parliament ; Therefore.We do hereby make it known that, by and with the advice of the Executive Council of the Province of Quebec.We have, this day.given orders for issuing Election Writs in due form, for constituting a new Legislative Assembly of the said Province, which Election Writs are all to bear date the eighteenth day of April 1966, and be returned before the tenth day of July 1966, the nomination of candidates at the election to be held and take place on the twenty-second day of June 1966, in all the electoral districts; and the holding of the polls to take place and be held on the fifth «lay of June 1966.in all the electoral districts.Ix testimony wheheof.We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of the Province of Quebec to be hereunto affixed, Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable Hugues Lapointe.p.c.q.c, Lieutenant-Governor of the said Province.At Our Government House, at Quebec, this eighteenth day «>f April, in the year of Our 2360 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 88 avril 1966, 98' année, n\" 16 neuf cent soixante-six et de Notre règne le quinzième.Par ordre.Le Secrétaire a**Q0ié île la Chancellerie à Québec, 14816-0 .Fioan denégal.Canada.Province de HUGUES LAPOINTE Québec.|L.S.| ELIZABETH DEUX» par la grâce de dieu, Reine du Royaume-l'ni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À nos très aimés et fidèles conseillers les membres du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de la province de Québec.balut.Proclamation A TTENDfJ que sur l'avis du Conseil exécutif * » de la province de Québec, Nous avons jugé à propos de dissoudre la présente législature de ladite Province; A ces causes, Nous dissolvons par les présentes ladite législature de la province de Québec.En foi dis quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de la province de Québec.témoin : Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable HrciiKs lapointe, o.p., ch.lieutenant-gouverneur de ladite Province.Donné en Notre hôtel du gouvernement, à Québec, le dix-huit avril, l'an de grâce mil neuf cent soixante-six et de Notre règne le quinzième.Par ordre.l4S16-o Le Secrétaire associé de la ( 'hancellerie à Québec.Jean Senegal.HUGUES LA POINT l bord one thousand nine hundred and s i x I > six and the fifteenth year of Our Reign.By command, Jean SENEGAL.Clerk Associate of the Crown 14816-0 mi Chanceri/.Quebec.( 'anada.Province of Quebec.]L.S.| ELIZABETH THE SECOND, by the Grace ol God, of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seus.Queen.Defender of the Faith.To Our Beloved and Faithful the members \"I the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Our Province of Quebec and to all to whom it may concern.Greeting.Proclamation YWlIEREAS We have thought fit.by and W with the advice of the Executive Council of the Province of Quebec, to dissolve the present Legislature of the said Province; Therefore, We do hereby dissolve the said Legislature of the Province of Quebec.In testimony whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of the Province of Quebec to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable hugues lapointe, p.c.q.< .Lieutenant-Governor of the said Province.At Our Government House, at Quebec, tM- eighteenth day of April, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and shtty-six and the fifteenth year of Our Reign.By command.Jean Senegal, Clerk Associate of the Crown I4NI0-o in Chancery, Quebec.Soumissions Tenders Paroisse de Notre-Dame-de-Laterrière Comté de Chicoutimi Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Normand Girard, sécrétaire-trésorier, jusqu'à ti heures p.m.à Blvd Talbot.Nolre-Damc-de-Laterrière, comté de Chicoutimi.P.Q.et par après de 7.30 heures p.m.à S heures p.m.à la Salle Publique, Collège de Laterrière.(Garçons), Rue Gauthier, Village de Laterrière.(Chicoutimi).P.Q., mercredi, le 11 mai 1900.pOUr l'achat de $95,000 d'obligations de la paroisse de Notre-Dame-de-Laterrière.comté de Chicoutimi, datées du 1er juin 1960 et remboursables par séries du 1er juin 1967 au 1er juin 19K6 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5^%, ni supérieur à 6%, payable seini-nnnuellcment les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement No 82 \u2014 $95,000 \u2014 aqueduc Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1966.Parish of Notre-Dame-de-Laterrière County of Chicoutimi Public notice is hereby given that sealed benders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will I» received by the undersigned Normand Girard, secretary-treasurer, until 6:00 o'clock p.m.ai Blvd.Talbot, Notre-Dame-de-Laterrière, county of Chicoutimi, P.Q., and afterwards from 7:30 o'clock p.m.to 8:00 o'clock p.m.at the Public Hall.Laterrière College (Boys).Gauthier Street.Village of Laterrière.(Chicoutimi).P.Q.Wednesday, May 11.1906, for the purchase of an Issue of $95,000 of bonds for the parish of Notre-Dame-de-Laterrière, county of Chicoutimi.dated June I, 1966, and redeemable serially from June I.1967 to June 1.1986 inclusively, with in teres I at a rate not less than 51£%, nor more than 0', payable semi-annually on June 1 and Decemhe: 1 of each year.The rate of interest may be tile same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-law No.82 \u2014 $95,000 - aqueduct.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from June 1, 1900. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 11)06, Vol.98, A7».10 2361 Tableau d'amortissement $95,000 20 ans Année Capital lor juin 1907.f 1.000 1er Juin 1068.1.500 Ut juin 1909.1.500 1er juin 1070.1.500 1er juin 1971.1,500 1er juin 1972.1,500 1er Juin 1973.1.500 1er juin 1974.2,000 1er juin 1975.2,000 1er juin 1970.2,000 1er juin 1977.2,000 1er juin 1978.2.500 1er juin 1979 .2,600 1er juin 1980 .2.500 1er juin 1981.2,600 1er juin 1982.3.000 1er juin 1983 .3,000 1er juin 1984.3,000 1er juin 1985.3,600 1er juin 1980 54,500 De plus, des soumissions pourront être envoyées et «-Iles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque vi*é, payable au pair à Chicoutimi.Ia: capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la hanqtie dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachctahlcs par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée \u2022 l'un chèque accepté égal à \\% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions sersnt ouvertes et considérées a une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 11 mai 1900.à 8 heures du soir, à la Salle Publique, Collège de Laterrière.(Garçons), Hue Gauthier, Village de Laterrière.comté de Chicoutimi, P.Q.Le conseil se réserve le droit «le n'accepter ni la plus haute ni aucune «les soumissions.Notre-Dame-de-Laterrière, (Comté de Chicoutimi), ce 18 avril 1900.Le Secrétaire-trésorier, Normand Giuaku.Blvd Talbot, Notre-Dame-de-Laterrière.(Chicoutimi), P.Q.Téléphone: 078-2529.code 418.14771-o Ville de Québec-Ouest Comté de St-Sauveur Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Roger Gauvin, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, 313, avenue Bélanger, Québec-Ouest, comté de St-Sauveur, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mercredi, le 11 mai 1966, pour l'achat de 8167,000 «l'obiigations de la ville de Quél>ec-Oue.st, comté de St-Sauveur, datées du 1er juin 1966 et remboursables par séries du 1er juin 1967 au 1er juin 1986 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5j^%, ni supérieur à 6%, payable semi-annuellement les Tabic of redemption $9S,0Q0 20 years Year Capital June 1, 1967 .8 1,000 June 1, 1968.1.500 June 1.1909 .1,500 June 1.1970.1,500 June 1,1971 .1.500 June 1,1972.1,500 June 1.1973.1.500 June 1, 1974.2.000 June 1.1975 .2,000 June 1.1970 .2,000 June 1.1977.2,000 June I.1978.2,500 June 1.1979 .2.500 June 1.1080 .2,600 June 1, 1981.2,500 June 1.19S2.3,000 June I.1083.3,000 June 1,1984.3,000 June 1.1085.3,-500 June 1, 10S6.54,500 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any.by by certified cheque payable at par at Chicoutimi.Capital and interest are payable at all branches in the province of Quebec of the bank mentione«l iu the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanietl by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their «leliverbis included or not in the price of the temler.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held OU Wednesday, May 11, 1900.at 8:00 o'clock p.m.at the Public Hall, Laterrière College, (Boys).Gauthier Street.Village of Laterrière.county of Chicoutimi, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Notre-Damo-«le-Laterrière.(County of Chicoutimi).April 18.1966.Normand Girard, Secretary-Treasurer.Talbot Blvd.Notre-Dame- nor more than 6%, payable semi-annually on June 1 and December 1, of each year.The 2302 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril I960, 93' année, «° 16 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le môme pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements Nos: 414 \u2014 $50,000 \u2014 trottoirs et chaiucs de rues; 415 \u2014 $04,000 \u2014 pavage; 420 \u2014 $35,500 \u2014 aqueduc, égouts, etc; 427 \u2014 15,500 \u2014 aqueduc et égouts; 433 \u2014 $12,000 \u2014 bâtisses et terrains.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1960.Tableau d'amortissement \u2014 9167,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1967.$14,000 1er juin 1968.15,500 1er juin 1969.16,000 1er juin 1970.16,500 1er juin 1971.17,500 1er juin 1972.7,000 1er juin 1973.7,500 1er juin 1974.7,500 1er juin 1975.8,500 1er juin 1976.9,000 1er juin 1977.3,500 1er juin 1978.4,000 1er juin 1979 .4,000 1er juin 1980.4,000 1er juin 1981.4,500 1er juin 1982.4,500 1er juin 1983 .5,500 1er juin 1984.5,500 1er juin 1985.6,000 1er juin 1986 .6,500 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations â courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Québec-Ouest.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à \\% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 11 mai 1966, à 8 heures du soir, Hôtel de ville, 313, avenue Bélanger, Québec-Ouest, comté de St-Sauveur, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Québec-Ouest, (Comté de St-Sauveur), ce 18 avril 1966.Le Secrétaire-trésorier, Roger Gauvin.Hôtel de ville, 313, avenue Bélanger, Québec-Ouest, (St-Sauveur), P.Q.Téléphone: 681-6217, code 418.14772-o rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos: 414 \u2014 $50,000 \u2014 sidewalks and curds; 415 \u2014 864,000 \u2014 paving; 420» $35,500 \u2014 aqueduct, sewers, etc.; 427 \u2014 86,500 \u2014 aqueduct and sewers; 433 \u2014 $12,000 buildings and terrains.For adjudication purposes only, interest shall l)c calculated as from June 1, 1966.Table of redemption $167,000 \u2014 20 years Year Capital June 1, 1967.$14,000 June 1, 1968.15,500 June 1, 19G9.16,000 .luiie 1, 1970.16,500 June I, 1971.17,500 June 1, 1972.7,000 June 1,1973 .7,500 June 1, 1974.7,500 June 1, 1975.8,500 June 1, 1976.9,000 June 1, 1977 .3,500 June 1, 1978.4,000 June 1, 1979.4,000 June 1, 1980.4,000 June 1, 1981.4,500 June 1, 1982 .4,500 June 1,1983.5,500 June 1, 1984 .5,500 June 1,1985.6,000 June 1, 1986 .6,500 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three ternis only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and acrued interest, if any, by certified payable at par at Quebec-West.Capital and interest are payable at lull branches in the province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not l>e redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certifie) 1 cheque equal to 1% of the amount of the preseid issue and must specify whether interest accrue» 1 on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Wed nesday, May 11, 1966, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 313 Bélanger Avenue, Quelioc-West, county of St-Sauveur, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Quebec-West, (Countv of St-Sauveur), April 18, 1966.Roger Gauvin, Secretary- Treasurer.Town Hall, 313 Bélanger Avenue, Quebec-West, (St-Sauveur), P.Q.Telephone : 681-6217, code 418.14772 Ville de Lac Mégantic Comté de Frontenac Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées < Sou- Town of Lake Mégantic County of Frontenac Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, I960, Vol.98, No.16 2368 missions pour obligations » seront reçues par le soussigné Hervé Fecteau, greffier, Hotel de ville, rue Frontenac, Lac Mégantic, comté de Frontenac, P.Q.jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 10 mai 1066, pour l'achat de $592,500 d'obligations de la ville de bue Mégantic, comté de Frontenac, datées du 1er juin 1966 et remboursables par séries du 1er juin 1967 au 1er juin 11)86 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5^j%, ni supérieur à 6%, payable \u2022¦emi-annuellement les 1er juin et 1er décembre «le chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements Nos: 333 \u2014 $2,500 \u2014 voirie; 352 S 107,000 \u2014 aqueduc; 353 \u2014 $11,500 \u2014 voirie; 354 \u2014 $27,000 \u2014 travaux à l'Hôtel de ville; 371 \u2014 $30,000 \u2014 acliat de terrain pour fins industrielles; 374 \u2014 $324,500 \u2014 aqueduc et ('\u2022gouts.Four fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1966.Tableau d'amortissement \u2014 $592,500 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1967.$21,500 1er juin 1968 .22,000 1er juin 1969 .23,000 1er juin 1970 .24,000 1er juin 1971.25,000 1er juin 1972 .27,000 1er juin 1973 .28,000 1er juin 1974.31,000 1er juin 1975 .33,000 1er juin 1976.34,000 1er juin 1977.26,000 1er juin 1978.27,000 1er juin 1979 .28,000 1er juin 1980 .29,000 1er juin 1981.31,000 1er juin 1982.32,000 1er juin 1983.,.34,000 1er juin 1984.37,000 1er juin 1985 .39,000 1er juin 1986 .41,000 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération |N)ur des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obliga-t ions, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par ehèque visé, payable au pair à Lac Mégantic.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lea soumissions seront ouvertes et considérées « une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 10 mai 1966, à 8 heures du soir, Hôtel de ville, rue Frontenac, Lac Mégantic, comté de Frontenac, P.Q.received by the undersigned Hervé Fecteau, clerk.Town Hall, Frontenac Street, Lake Mégantic, county of Frontenac, P.Q., until 8:00 O'clock p.m.Tuesday, May 10.1900, for the purchase of an issue of $592,500 of bonds for the town of Lake Mégantic, county of Frontenac, dated June 1, 1966.and redeemable serially from June 1.1967 to June 1.1986 inclusively, with interest at a rate not less than 5^2%.nor mote than 6%.payable semi-annually on June 1 and December 1 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos: 333 $2.500 roads; 352 $197.000 - aqueduct; 353 - $11,500 roads; 354 - 827,000 \u2014 works at the Town Hall; 371 $30,000 buying of land for industrial purposes; 374 8324.500 aqueduct and sewers.For adjudication purposes only, interest shall he calculated as from June 1.1966.Table of redemption $502.500 20 year.s Year ( apital June 1.1967.$21.500 June I, 1908 .22,000 June 1.1969 .23,000 June 1, 1970.24,000 June 1.1971.25,000 June 1,1972.27.000 June 1.1973 .28,000 June 1.1974 .31,000 June 1, 1975.33,000 June 1,1976.34,000 June 1, 1977.26,000 June 1, 1978 .27,000 June 1.1979.28,000 June 1,1980.29.000 June 1,1981.31,000 June 1, 1982 .32,000 June 1,1983.34.000 June 1, 1984.37,000 June 1,1985 .39,000 June 1,1986 .41,000 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Lake Mégantic.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank whose name is mentioned in the loan procedure as well as at the principal office of the said bank in Toronto.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council, to be held on Tuesday, May 10, 1966, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, Frontenac Street.Lake Mégantic, county of Frontenac.P.Q. 2304 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril 198$, 98* année, n° 10 Ix! conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des souinmissions.Lac Mégantic, (Comté de Frontenac), ce 18 avril 1900.Le Greffier, Hehvé Fbctbau.Hôtel de ville, Rue Frontenac, C.P.129, bac Mégant ir, (Frontenac), P.Q.Téléphone: 583-2441, code S19.14808-n Cité de Saint-Jérôme ( ointe de Terrebonne Avis publie est pur les présentes donné que mté «le Torrc- honne, P.Q.l,c conseil s«' réserve le droit «le n'accepter ni la plus haute ni aucune «les soumissions.Saint-Jérôme.(Comté «le Terrebonne), ce 19 avril 1Ô86.Le Greffier.GÉRARD Maiiiici:.Hôtel «le Ville, 280.rue Labelle, Saint-Jérôme, (Terrebonne), P.Q.Téléphone : 438-3950.code 514.14S09-o Ville St-Pierre Comté «le Jao«pii\\s-Cartier Avis public est par les présentes donné «pie des soumissions <-aehett!es et endossées « Soumissions pour «)bligati«)iis seront reçues par le soussigné Gérard Goyettc, seerétaire-tré.sorier, Hôtel «le Ville.69, âième avenue.Ville St-Pierre, comté <1«' Jacques-Cartier, P.Q.jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 10 mai 1000, pour l'achat de $311,000 «l'obligations «le Ville St-Pierre.comté de Jacques-Cartier, datées «lu 1er juin 1900 et remboursables par séries du 1er juin 1907 au 1er juin 19H0 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5'ni supérieur à 0%, payable seini-annucllcment les 1er juin et 1er décembre de chaque aimée.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements Nos: 370 $101.000 aquetluc et voirie; 373 \u2014 $25,500 - aqueduc, égouts et voirie; 375 \u2014 $97,500 achat d'immeubles; 379 \u2014 $27.000 \u2014 a«'hat «l'un camion-pompe à incendie.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter «lu 1er juin 1900.Tableau d'amortisse ment S311.000 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1907.$13,000 1er juin 1908.14,000 1er juin 1909.14,000 1er juin 1970.11,000 1er juin 1971 .12.000 1er juin 1972.13.000 1er juin 1973.13,000 1er juin 1974.13,000 1er juin 1975.13,000 1er juin 1976.14,000 1er juin 1977.13.000 1er juin 1978.14.000 1er juin 1979.15,000 1er juin 1980.10,000 1er juin 1981.18,000 1er juin 1982 .20.000 1er juin 1983.21.000 1er juin 1984.21.000 1er juin 1985.21,000 1er juin 1986.22,000 On est prié «le noter que les soumissions sont \u2022h-mantlécs pour «les obligations remlwursables The said bonds will not l>c re«leemable by anticipation.Each temler must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrue*! on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will Ih> opened and consulercd at a meeting of the council to be held on Monday, May 9, 1966, at 8:30 o'clock p.m., at the City Hall, 280 Labelle Street, Saint-Jérôme, county of Terrebonne, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Saint-Jérôme, (County of Terrelxmne), April 19, 1966.Gérard AIaukice, City Clerk.City Hall, 280, Labelle Street, Saint-Jérôme, (Terrelxmne), P.Q.Telephone : 438-3950, code 514.14800 Town of St-Pierre County of Jacques-Cartier Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Gérard Goyette, secretary-treasurer, Town Hall, 69, 5th Avenue, Town of St-Pierre, county of Jacques-Cartier, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., Tuesday, May 10, 1966, for the purcliase of an issue of $311,000 of bonds for the Town of St-Pierre, county of Jacques-Cartier, dated June 1, 1966, and redeemable serially from June 1, 1967 to June 1, 1986 inclusively, with interest at a rate not less than 5)^%, nor more than 6%, payable semi-annually on June 1 and December 1 of each year.The rate of interest may l)e the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos.370 \u2014 $161,000 \u2014 aqueduct ami roads; 373 \u2014 $25,500 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 375 \u2014 $97,500 \u2014 purchase of immoveables; 379 \u2014 $27,000 \u2014 purchase of a fire truck.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from June 1, 1966.Table of redemption \u2014 8311,000 \u2014 20 years Year Capital June 1, 1967.$13,000 June 1, 1968.14,000 June 1, 1969.14,000 June 1,1970.11,000 June 1,1971.12,000 June 1, 1972.13,000 June 1, 1973.13,000 June 1,1974.13,000 June 1,1975.13,000 June 1, 1976.14,000 June 1,1977.13,000 June 1, 1978.14,000 June 1, 1979.15,000 June 1, 1980.16,000 June 1, 1981.18,000 June 1, 1982 .20,000 June 1,1983.21,000 June 1, 1984.21,000 June 1, 1985.21,000 June 1, 1986.22,000 Please note that tenders are called for bonds redeemable according to the above table only, 2366 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.03 avril 1990, OS' année, n° 16 suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront laites pour «les obligations à courte échéance ne s«'cout pas prises en considération.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations.capital et intérêts Courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Montréal, Le capital et les int«;rêts sont payables à Umtcs les succursales dans la province «le Québec «le la hampic dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de latlite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas racbetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagne»' «l'un chèque accepté égal à 1% «lu montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix Offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment «le leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à line séance «lu conseil «pli sera tenue mardi, le 10 mai 1000.à S heure» «lu soir.Hôtel «le Ville.09, ôième avenue.Ville St-Pierre, comté de Jacques-Cartier, P.Q.Ix> conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni uucuuc des soumissions.St-Pierre.(Comté de .lace taken into consideration.The successful tenderer agrees t«) pay for t be bonds, principal ami accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Alontreal.Capital and interest are payable at all branches in the province of Quebec of the bank mentioned iu the loan procedure as well as at the principal oflice of the sai«I bank in Toronto.The said Ixmds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanic«l by a certified cheque equal t«> 1% of the amount of the present issue and must specify whether in le.rest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will l>e opened and considered at a meeting of the council to be held on Tuesday, May 10, 1906, at 8:00 o'clock p.m.at the Town Hall, 69, 5th Avenue.Town of St-Pierre, county of Jacques-Cartier, P.Q.The council does not bind itself to accept t lie highest or any of the tenders.St-Pierre, (County of Jac«jues-Carticr), April 19, 1966.GERARD Goykttk.Secretari/- Treasurer.Town Hall, 69, 5th Avenue, Town of St-Pierre, (Jacques-Cartier), P.Q.Telephone : 489-579Ô.code 514.14810 Municipality of Touraine County of Gatineau I Formerly: Township of Hull.East part Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will he received by the undersigned André Prud'homme, secretary-treasurer.Town Hall.12 Picardie Avenue.Touraine.Via Pointe-( Jatineau.county of Hull.P.Q.until 8:00 o'clock p.m.Monday.Alay 9, 1900, for the purchase of an issue <>f 8331.000 of bonds for the municipality of Touraine.county of Gatineau.dated June 1.1966, ami redeemable serially from June 1, 1907 t<> June 1, 1980 inclusively, with interest at a rate not less than 5,'\u2022>%, nor more than 6%, payable semi-annually OU June 1 ami December 1 of each year.The rate of interest may he the same for the whole issue or it may vary according t<> maturities.By-law Nos: 312 832,000 buying of machinery; 315 (319) 818.000 asphalt curbs;310 - 813.000 -roads;324- -8225.000 aqueduct; 330 \u2022 88,000 buying of equipment; 334 812.000 ¦ -aqueduct; 335 $13.000 -aqueduct ; 339 - 810,000 buying of machinery.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from June 1.1900.Table of redemption $331.000 20 years Y'ear Capital June 1, 1967.S 16.000 June 1, 1908.16.000 June 1, 1969.16,500 June 1, 1970.10,500 June 1, 1971.11.000 June 1.1972.8,000 June 1, 1973.8,500 June 1, 1974.8.500 June 1, 1975.8,500 June 1.1976.9.000 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, im, Vol.98, Ho, w 2367 1er juin 1977.$ 4,000 1er juin 197S.4.000 1er juin 1979.4,000 1er juin 1980 .4,500 1er juin 1981 .4,500 1er juin 1982 .4,500 1er juin 1983.5,000 1er juin 1984 .5,000 1er juin 1985.5.500 1er juin 1980.177,500 I )e plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en consideration pour des obligation!) à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Hull.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto et à Ottawa.Lesdites obligations ne seront pas rachetablcs par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées a une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 9 mai 1966) à S heures du soir.Hôtel de Ville.12 avenue de Picardie, Touraine, comté de Gatineau.P.Q.Ia?conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Touraine.(Comté de Gatineau).ce 18 avril 1966.Le Secrétaire-trésorier, André: Prud'homme, Hôtel de Ville.12 avenue de Picardie.Touraine, Via Pointe-Gatineau, (Hull).P.Q.Téléphone : 771 -5608, code 819.14811 -o Municipalité de Val Morin Comté de Terrebonne Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné J.B.Vanier, secrétaire-tréscrier, jusqu'à 6 heures p.m.à 103, rue Alorin, Val Morin.comté de Terrebonne, et par après de 7.30 heures p.m.à 8 heures p.m.à la Salle paroissiale.Val Morin.comté de Terrebonne.P.Q., mardi, le 10 mai 1900.pour l'achat de 8121.000 d'obligations de la municipalité de Val Alorin, comté de Terrebonne, datées du 1er juin 1966 et remboursables par séries du 1er juin 1967 au 1er juin 1986 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5H%« nx supérieur à 6%, payable Mini-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements Nos: 65 - 831,000 voirie; 66 874,000 \u2014 aqueduc; 72 \u2014 816,000 voirie.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1966.Tableau d'amortissement SI21,000 20 ans Année Capital 1er juin 1967.$ 3,500 1er juin 1968 .3,500 .lune 1, 1977.S 4,000 June 1, 1978.4,000 .lune 1, 1979.4,000 .lune 1, 1980.4.5(H) .lune 1, 1981 .4,500 June 1, 1982 .4,600 June 1, 1983.5,000 June 1, 1984.5,000 June 1, 1985.5,500 June I, 1980.177.500 Moreover, tendra may be forwarded ami shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be Considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Hull.Capital and interest arc payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank whose name is mentioned in the loan procedure as well as at the principal office of the said bank in Toronto and Ottawa.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, Alay 9, 1966, at 8:00 o'clock p.m.at the Town Hall, 12 de Picardie Avenue.Touraine.county of Gatineau, P.Q.The council is not bound to accept the highest or any of the tenders.Touraine.(County of Gatineau), April 18.1900.André Prud'homme, Secretary-Treasurer.Town Hall.12 de Picardie Avenue.Touraine, Via Pointe-Gatineau, (Hull), P.Q., Telephone: 771-5668, code 819.14811 Municipality of Val Morin County of Terrebonne Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will l>e received by the undersigned J.B.Vanier, secretary-treasurer, until 6:00 o'clock p.m.at 103 Morin Street.Val Morin.county of Terrebonne, ami after from 7:30 o'clock p.m.to 8:00 o'clock p.m.at the Parochial Hall.Val Alorin, county of Terrebonne.P.Q., Tuesday, May 10.1966.for the purchase of an issue of 8121.000 of bonds for the municipality of Val Alorin, county of Terrebonne, dated June 1.1900, and redeemable serially from June 1, 1907 to June 1.1980 inclusively, with interest at a rate not less than 51-2%.nor more than 6%, payable semi-annually on June 1 and December 1 of each year.The rate of interest may l>e the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos: 65 - 831.000 \u2014 roads; 66 -874,000 \u2014 aqueduct; 72 - 816,000 \u2014 roads.For adjudication purposes only, interest shall lie calculated as from June I, 1900.Table of redemption - $121,000 \u2014 20 years Year ( apital June 1, 1907.8 3,500 June t, 1968 .3,500 2368 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril 1900, 98' année, n° 10 1er juin 19(H).$ 4.000 Ut juin 1970 .4.000 1er Juin 1971.4.000 1er juin 1972.4.000 1er juin 1973.4.500 Ut juin 1974 .5.000 Ut juin 1975.6,000 1er juin 1970.0.000 Ut juin 1977.0.000 1er juin 197S.0.500 Ut juin 1979 .0,500 1er juin 1980.7,500 Ut juin 1981 .7.500 Ut juin 1982.8.000 1er juin 1983.8.000 Ut juin 1084.8,500 Ut juin 1985 .9,000 Ut juin 1980.10.000 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Ste-Agathe-des-Monts.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 10 mai 1900.à 8 heures du soir, 103, rue Morin.Val Morin, comté de Terrebonne.P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Val Morin, (Comté de Terrebonne), ce 20 avril I960.Le Secrétaire-trésorier, j.B.Vanikh.103, rue Morin Val Morin, (Terrebonne), P.Q.Téléphone: 322-2143, code 819.14812-o Ville de Villeneuve Comté de Québec Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Daniel Leclerc, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, 95, rue Savio, Villeneuve, comté de Québec 5, P.Q., lundi, le 9 mai 1966, jusqu'à 8.30 heures du soir, pour l'achat de $467,000 d'obligations de la ville de Villeneuve, comté de Québec, datées du 1er juin 1966 et remboursables par séries du 1er juin 1967 au 1er juin 1986 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à ni supérieur à 6%, payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.lune 1.1909.$ -1.000 .lune 1.1970.4.000 .lune 1.1971 .4.000 .lune 1.1972 .4.000 .lune 1.1973.4.501) June 1.1974.5.000 .lune 1.1975.5.000 \u2022lune 1.1970 .6,000 \u2022lune I.1977.0.000 .lune 1.1978.0.500 .lune 1.1979.0.500 .lune l, 1980.7,500 .lune 1.1981 .7.500 .lune 1.1982.8,000 .lune 1.1983.8,000 June 1,1984.8,500 June 1.1985.9.000 June 1.1980.10.000 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three ternis only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any.by certified cheque payable at par at Ste-AgatIndes-Monts.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the hank whose name is mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Bach tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council, to be held on Tuesday.May 10, 1900.at 8:00 o'clock p.m.a( 103 Morin Street.Val Morin.county of Terrebonne.P.O.The council is not bound to accept the highest or any of the tenders.Val Alorin.(Count v of Terrebonne).April 20.1900.J.B.Vaniku.Secretari/-Treasurer.103 Alorin Street, Val Alorin.(Terrebonne), P.Q.Telephone: 322-2143.code 819.14812 Town of Villeneuve County of Quebec Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Daniel Lelccre.secretary-treasurer.Town Hall, 95 Savio Street.Villeneuve, county of Quebec 5, P.Q., Monday, May 9, 1966.until 8:30 o'clock p.m.for the purchase of an issue of $467.000 of bonds for the Town of Villeneuve, county of Quebec, dated June 1, 1966, and redeemable serially from June 1, 1967 to June 1.1986 inclusively, with interest at a rate not less than 6%%, nor more than 6* < \u2022 payable semi-annually on June 1 and December 1 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities. QUEBEC OFFK'IAL GAZETTE, April 23, 1966, Vol.98, \\o.16 2366 Règlement» Nos: 152 \u2014 $324,500 \u2014 aqueduc, «goûts, voirie; 157 \u2014 $142,500 \u2014 aqueduc et égouts.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1966.Tableau d'amortissement - $467,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1967.$ 5,000 1er juin 196S.5,000 1er juin 1969.6,000 1er juin 1970.6.000 1er juin 1971.7,000 1er juin 1972 .7,000 1er juin 1973 .8,000 1er juin 1974.8,000 1er juin 1975 .8,000 1er juin 1970.9,000 1er juin 1977.9,000 1er juin 1978.10,000 1er juin 1979.11,000 1er juin 1980.12,000 1er juin 1981.12,000 1er juin 1982.13,000 1er juin 1983.13,000 1er juin 1984.15,000 1er juin 1985.16,000 1er juin 1986 .287,000 De plus, des soumissions |>ourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Québec.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le '¦' mai 1966, à 8.30 heures du soir, Hôtel de Ville, 95, rue Savio, Villeneuve, comté de Quél>ec 5, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Villeneuve, (Comté de Québec), ce 20 avril 1966.Le Secrétaire-trésorier, Daniel Leclerc.Hôtel de Ville, 95, rue Savio, Villeneuve, (Québec 5), P.Q.Téléphone: 663-6987, code 418.14813*0 By-law Nos: 152 $324,500 aqueduct, sewers, roads; 157 $142,500 - aqueduct and sewers.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from June 1.1900.Table of redemption ¦ $',67,000 20 yearn Year Capital June 1, 1967.$ 5.000 June I, 1968 .5.000 June 1.1969 .6.000 June 1, 1970.6,000 June 1.1971.7.000 June 1.1972.7.000 June 1.1973 .8,000 June 1, 1974 .8,000 June 1, 1975.8.000 June 1, 1976 .9,000 June 1.1977.9,000 June 1.1978.10,000 June 1, 1979.11,000 June 1, 1980.12,000 June 1, 1981.12,000 June 1.1982.13,000 June 1.1983.13,000 June 1.1984.15,000 June 1, 1985.16,000 June 1.1986.287.000 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Quebec.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank whose name is mentioned in the loan procedure as well as at the principal office of the said bank in Toronto.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, May 9, 1966, at 8:30 o'clock p.m.at the Town Hall.95 Savio Street.Villeneuve, county of Quebec 5.P.Q.The council is not bound to accept the highest or anv of the tenders.Villeneuve, (County of Quebec), April 20, 1966.Daniel Leclerc.Secretary-Treasurer.Town Hall.95 Savio Street.Villeneuve, (Quebec 5), P.Q.Telephone: 663-6987.code 418.14813 Syndicat professionnel Professional Syndicate Vssociation des policiers provinciaux du Québec ( Loi des syndicats professionnels) La constitution «l'un syndicat professionnel, sous le nom de « Association des policiers provinciaux du Québec », a été autorisée par le Secré- Assoeiation des policiers provinciaux du Québec (Professional Syndicates Act) The incorporation of a professional syndicate, under the name of \"Association des policiers provinciaux du Québec\", bas been authorized 2370 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.23 avril 1966, OS' année.n° 16 luire de lu province le 5 uvril 1900.I«e siège social dudit syndicat professionnel est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal.Québec, le 7 avril 1900.Le SouK-necrêtairc de la province.Raymond Douville.14735-u 14-00 by the Provincial Secretary on April ô.IDi'.ii.The bead office of the said professional syndicate is situated at Montreal, judicial district of Quebec.Quebec.April 7.1900.Raymond Doi villi.As.sintant Secretary of the Prorince.14735 14-66 Vente d'effets non-rcclatnés Sale of Unclaimed Goods Canadian Pacific Express Company Avis est par les présents donné que tous les effets reçus avant le 1er jour de mai 1965, et non réclamés aux bureaux de la Canadian Pacific Express Company, à divers endroits «le la province de Quebec, seront vendus aux enchères publiques au plus haut enchérisseur par Frank Wadding ton, encanteur, 128 est, rue King, Toronto, à onze heures du matin, le cinquième jour de mai 1966, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.Québec, Que., le 15 mars 1966.Canadian Pacific Express Company Le Surintendant général, 14345-1 l-6-o E.M.TttABHEB.Canadian Pacific Express Company Notice is hereby given that all goods received previous to the 1st day of May 1965, and still remaining unclaimed in the offices of the Canadian Pacific Express Company, at different points in the Province of Quebec, will l>e sold at public auction to the highest bidder by Frank Wadding-ton, Autioneer, at 128 King Street East, Toronto, Ontario, at 11:00 o'clock in the forenoon, on the 5th day of May 1966, unless same shall Ik* called for before that date and all charges paid thereon.Quebec, Que., March 15.1966.Canadian Pacific Express Company E.M.Tbashbr, 14345-11 -6-o (lateral Superintendent.Vente par licitation Sale by Licitation Les Immeubles Rouville Inc.vs Morin et vir Les Immeubles Rouville Inc.is Alorin et vir Province de Québec, district de St-Hyacinthc, Cour supérieure No 17,244, Les Immeubles Rouville Inc., corps politique et incorporé, légalement constitué, ayant son siège social et une place d'affaires en les cité et district de St-Hyacinthe, demanderesse, vu Dame Simone Alorin, des cité et district de St-Hyacinthc, épouse de Aie Alaurice Rousseau, des mômes lieux et ce dernier aux fins d'autoriser son épouse si besoin est, défenderesse.Apia de licitation Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour supérieure siégeant à St-Hyacinthe, dans le district de St-Hyacinthe, et rendu par l'Honorable Juge Paul Langlois, le 7 mars 1966, dans une cause en laquelle Les Immeubles Rouville Inc., corps politique et incorporé, légalement constitué, ayant son siège social et une place d'affaires en les cité et district de St-Hyacinthe, est demanderesse, et Dame Simone Alorin, des cité et district de St-Hyacinthe, épouse de Me Maurice Rousseau, des mêmes lieux, est défenderesse, ordonnant la licitation de l'immeuble désigné comme suit : « 1° Un terrain situé à Douville, rue Bachand, désigné comme étant la subdivision No huit du lot originaire No mille quatre-vingt-dix-sept au cadastre de la paroisse Notre-Dame de St-Hyacinthe, mesurant trente-trois pieds de largeur sur cent un pieds et cinq dixièmes de pied de profondeur, le tout à la mesure anglaise; 2° Un terrain situé à Douville, désigné comme faisant partie du lot No mille quatre-vingt-dix-sept (ptie 1097) au cadastre de la paroisse Notre-Dame de St-Hyacinthe, mesurant quatre cent quarante-sept pieds et quarante-six centièmes Province of Quebec, district of St-Hyacintlie.Superior Court No.17.244, Les Immeubles Rouville Inc.body politic and corporate, legally incorporated, having its head office and business place in the city and district of Sl-Hyacinthe, plaintiff, r.s Airs.Simone Alorin, of the city and district of St-Hyacinthe, wife of Ale Alaurice Rousseau, of the same place and the latter to authorize his wife if necessary, defendant.Notice of licitation Notice is given that in virtue of a judgment of the Superior Court sitting in St-Hyacinthe.in the district of St-Hyacinthc.and rendered by the Honourable Judge Paul Langlois.on March 7, 1966.in a case in which Les Immeubles Rouville Inc., hotly politic and corporate, legally incorporated, having its bead office and business place in the city and district of St-Hyacinthe.is the plaintiff, ami Airs.Simone Alorin.of the city and district of St-Hyacinthe, wife of Me Alaurice Rousseau, of the same place, is the defendant, ordering the licitation of the immoveable designated as follows: « 1.A piece of land situated at Douville.Bachand Street, disignated as being subdivision No.eight of original lot No.one thousand and ninety-seven of the cadastre of the parish <>f Notre-Dame de St-Hyacinthe.measuring thirty-three feet in width by one hundred and one feet ami five tenths of a foot in depth, the whole English measure; 2.A piece of land situated at Douville, designated as being part of lot No.one thousand and ninety-seven (Pt.1097) of the cadastre of the parish of Notre-Dame «le St-Hyat hit he.measuring four hundred and forty-seven feet QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 1906, Vol.1)8, No.to de pied au sud-est; deux mille deux cent vingt-six pieds et trente-six centièmes de pied au nord-estî sept cent six pieds et trois centièmes de pied au nord-ouest; la ligne latérale sud-ouest du terrain présentement désigné, étant une ligne luisée longeant la ligne nord-est du lot mille <|iiutre-vingt-dixdiuit du cadastre a purtir du coin ouest dudit lot mille quatre-vingt-dix-sept-liiiit, jusqu'au terrain «les Chemins de Fers Nu-l m maux du Canada, le tout ù lu mesure anglaise, plus ou moins, sans guruntic de mesure précise, le plus ou le moins devunt tourner uu profit ou à lu perte «le l'acquéreur quelque soit lu différence, et tenant à un bout, au nord-ouest, au terrain «les Chemins de Fers Nationaux du Canada, ù l'autre bout, au su«l-est, au lot 1097-1, 2, 3, I, ô, 0, 7, et 8 or«lereau sous le numéro B37.Egalement une servitude «le droit de passage et servitude à perpétuité pour les lignes électriques «le Southern Canada Power consenti par l-'ry Cadhury Ltd., suivant acte enregistré au même endroit sous le numéro 104340.b'immeuble ci-haut désigné sera mis à Penchera et octroyé au plus haut enchérisseur le VINGT-HUITIEME jour de MAI 1906, à DIX heures TRENTE «le l'avant-midi, au hu-reau «lu protonotaire «le la Cour supérieure au palais de justice à St-Hyacinthe, ou dans toute autre salle tel que requis par les circonstances, sujet aux charges, clauses et conditions mentionnées «lans le cahier des charges déposé au greffe du protonotaire de la Cour supérieure.Toute opposition à fin d'annuler, à fin de charge <\"i à fin de distraire, à ladite licitation devra être déposés au greffe du protonotaire de ladite cour au moins 12 jours avant la date fixée comme susdit pour la vente et adjudication, et que toute opposition à fin de conserver devra être déposée ¦lans les six jours après l'adjudication, et à défaut par les parties de déposer ladite opposition dans les délais prescrits ci-dessus, elles seront forecloses de droit de le faire.Un dépôt égal au dixième de l'évaluation m\"ni-eipale de ladite propriété sera exigé avant la vente de chaque et tout enchérisseur.St-Hyacinthe, 18 avril 1006.and forty-six hundredths of a foot «m the southeast, two thousand two hundred and twenty-six feet ami thirty-six hundredths of a foot on the north-east, seven hundred and six feet ami three hundredths of a foot on the north-west; the south-west lateral line of the land presently designated, being a broken line along the northeast line of lot one thousand ami ninety-eight of the cadastre starting from the west COmer Of said lot «>nc thousand and ninety-seven - eight, up to the land of the Canadian National Railway, the whole English measure, more or less, without garant y of precise measurement, the more or the less turning to the profit or the loss of the purchaser however gr«'at the difference, and holding at cue end.on the north-west, by the land of the Canadian National Railway, on the other side, on the south-east, by Jot 1097-1, 2, 3, 4, 5, 0, 7 and 8 of the said cadastre, on one side on the north-east, by another part of said lot 1097 belonging to the Government of the Province of Quebec ami on the other side, on the south-west, by part of lot 1098 of the same cadastre.\" Together with a lease in favor of Southern Canada Power Co.Ltd.,giving the right to build an electrical transmission line and the right for 99 years, from and after March 31, 1917.to erect posts, lay wires, the right to make all necessary works, passing rights, etc .according to the registere«l deed at St-Hyacinthe under number B61811.Also a mortgage by Southern Canada Power Co.Lt«l.in favor of Alontreal Trust Co.to garanty the issuance of obligations of 850,000,000.entailing and affecting the rights acquired by Southern Canada Power Co.Ltd.on lot 1097 following registered deed at the same place by bordereau under number B37.Also a servitude of right of passage and servitude to perpetuity for the electric lines of Southern Canada Power consented by Fry Cad bury Ltd., following registered deed at the same place under number 104340.The above described immoveable will be sold by auction and granted to the highest bidder on the TWENTY-EIGHTH day of MAY, 1966.at TEN THIRTY o'clock in the morning, at the office of the Prothonotary of the Superior Court at the Court House of St-Hyacinthe, or in any other hall such as required for the circumstances, subject to charges, clauses and conditions mentioned in the list of charges filed in the office of the Prothonotary of the Superior Court.Any opposition to annul, to secure charges or to withdraw to be made to the said licitation must be filed in the office of the Prothonotary of the said court at least 12 «lays before the date fix«'«l as aforesaid for the sale and adjudication, ami any opposition for payment must be filed within six «lays following the adjudication; and failing the interested parties to file the suid opposition with the delay hereby prescribed, they shall be foreclosed from so doing.A deposit equal to «me tenth of the municipal evaluation of the said property will be required before the sale of each ami every bidder.St-Hyacinthe.April 18.1966.Le Procureur de la demanderesse, II780-16-2-o Mk Michel Pothibr.14780-16-2 Mk.Michel Pothibr, Attorney for the plaintiff. 2372 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril 1966, .%\" année, n° 16 Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.BEAUCE Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec District, de Beauce Cour Supérieure, f pLERMONT GRONDIN, No 32,39-1.S entrepreneur en trans-' port, de St-Frédéric, comté de Beauce, demandeur; vs PAMPHILE RODRIGUE, de St-Georges, comté de Beauce, défendeur.Pour être vendu « en bloc » l'immeuble ci-après décrit: « Un emplacement dans la 12ième rue ouest qui est partie des lots 07-26 et 07-25.» Pour être vendu « en bloc » à la porte de l'église paroissiale de St-Georges Ouest, comté de Beauce, le DIX-SEPTIÈME jour de MAI, 1966 à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le Député-Shérif, St-Joseph de Beauce, Adalbert Lessard.le 24 mars 1966.14512-13-2-o [Première insertion: 9 avril, 1966] [Deuxième insertion: 30 avril, 1966] Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Quéln-c District de Beauce ( our Supérieure, ( T ^OFFICE DU CRÉDIT No 32,257.«( ¦L' AGRICOLE DU QUÉ-l BEC, corps politique et in-<\"orj)oré ayant son siège social à Québec, demanderesse, M ODILAS PAQUET, cultivateur de St-Phihlx'rt, comté de Beauce, résidant à St-Prospcr, r.r.1, comté de Beauce, défendeur.Pour être vendus « en bloc » les immeubles ci-après décrits: « Le lot numéro quarante-cinq, rang A (45 rg.A) canton Linière, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.b) La demie sud-ouest du lot numéro quarante, rang B, {*/> S.O.40) canton Linière, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, à distraire: Un morceau de teirain, sans bâtisses, faisant partie de la demie sud-ouc: t du lot quarante, rang B (ptie de $\u2022\u2022> S.O.rang B) canton de Linière.Borné au sud-ouest par le lot quarante et un du même rang, au nord-ouest par Arthur Paquet ou par le trait carré des rangs B et quatre, au nord-est par AIIhtI Loignon ou par la demie-nord-est dudit lot quarante, au sud-est par Odilas Paquet ou par partie dudit lot quarante.Ledit morceau de terrain présentement réservé a en largeur celle correspondant à la demie sud-ouest dudit lot quarante, rang B, et en profondeur la longueur de huit (S) arpents.c) Le lot numéro trente-neuf (39) du rang B, canton de Linière, avec bâtisses dessus con>-truites, circonstances et dépendance.1, moins le terrain qui a déjà été vendu pour servir à la construction de la route actuelle.» Sheriffs' Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respect ive times and places mentioned below.BEAUCE Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Beauce Superior Court, ( pLERMONT GRONDIN.No.32,394.\\ transport contractor, of ' St-Frédéric, county of Beauce, plaintiff, Of PAMPHILE RODRIGUE, of St-Georges, county of Beauce, defendant.The immovable hereinafter described is to be sold \"en bloc\": \"An emplacement on 12th Street West which is part of lots 67-26 ami 67-25.\" To he sold \"en bloc\" at the parochial church door of St-Georges West, county of Beauce, on the SEVENTEENTH day of MAY, 1966, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Adalbert Lessard, St-Joseph de Beauce, Deputy-Sheriff.March 24, 1966.14512-13-2 [First insertion: April 9, 1966] [Second insertion: April 30, 1966] Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quel>cc District of Beauce Su|>erior Court, ( rTH E Q U E B E C F A It SI No.32,257.S A CREDIT BUREAU, ' body politic and corporate, having its head office in Quel>ec, plaintiff; r* ODILAS PAQUET, farmer, of St-Philibert, county of Beauce, residing at St-Prosper, R.R.1, county of Beauce, defendant.The immovables hereinafter described, to be sold \"en bloc\" : \"Lot number forty-five, range A (45.range A), township of Linière, with the buildings thereon constructed, circumstances and dependencies.(b) The southwest half of lot number forty, range B, (S.W.12 °f 40), township of Linière.with the buildings thereon con: tructed, circumstances and dependencies; to be withdrawn: A piece of land, without buildings, forming part of the southwest half of lot forty, range K (P.S.W.14, range B), township of Linière.bounded on the southwest by lot forty-one on the same range, on the northwest by Arthur Paquet or by the \"trait carré\" of ranges B and four, on the northeast by Albert Loignon or by the northeast half of said lot forty, on the southeast by Odilas Paquet or by part of said lot forty\u2022 The said piece of land presently reserved measures, in width, that corresponding to the southwest half of said lot forty, range B, and, in depth, eight (8) arpents.(c) Lot number thirty-nine (39), range B, township of Limière, with the buildings thereon constructed, circumstances and dependencies, less the terrain already sold for use in the construction of the present highway.\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23.1966, Vol.93, No.Hi 2373 Pour être vendus « en bloc » ù la poite de l'église paroissiale de St-Philibert, comté de Beauce, le DIXIÈME jour de MAI, 1966, à DIX heures de Pavant-midi.Bureau du Shérif, Le Député-Shérif, St-Joseph de Beauce.adalbert Lessard.le 23 mars, 1966.14513-13-2-o [Première inseition: 2 avril, 1966] [Deuxième insertion: 23 avril, 1966] Fieri Facias de Terris ( 'auada \u2014 Province de Québec District «le Beauce (r occult, affecting the said immoveable, according to titles.\" To In* sold at the parochial church «loor of the town of Saint-Joseph de Beauce.county of Beauce.on the THIRTY-FIRST day of MAY.1000.at TEN o'clock in the morning.Adalbert Lessard, Sheriff's Office, Deputy-Sheriff.Town of St-Joseph «le Beauce, April 12, 1966.14775-16-2 ] First insertion: April 23.1966] ]Second insertion: Slay 14.1966| BEDFORD Canada \u2014 Province of Quebec District of Bedford Superior < ourt.i A R M A N I) DO U C E T.No.14,586.\\ manufacturer, domi- \" oiled in the city of Saint-John, «listrict of Iberville, and therein carrying on business under the style ami name of St.Johns Window Inc.plaintiff, rs ARMAND FLEURY, domiciled at Venise-en-Québec, in the «listrict of Bedford, defendant.\"A certain piece of land situated in the municipality of Venise-en-Québec, county of Missisquoi, designated on the official plan and book of reference of the parish of St-Georges «le Clarence-ville, umler part of lot number one hundred ami fifty-two (Pt.No.152); this said piece of land being described as follows: Starting on the east sitle of the public road (along such public road) leading from Venisc-en-Québec, tt> St-Sébastien «l'Iberville, a distance of four hundred and eighty feet (480') on the north of the northwest corner of a part of the same lot No.152 sold by the present vendor to Mr.Leopold Bouchard, called starting point; thence along the public road, toward the north, a distance of one hundred feet (100') up to a point, thence toward the east at right angle, a distance of three hundred feet (300') up to a 237-1 Gazette officielle di: Quebec, m ami nm, w année, n° m île là vers le sud, à angle droit et parallèlement avec ledit chemin public, une distance de tent pieds (lt)O') jusqu'à un point; de là vers l'ouest à angle droit, une distance de trois cents pieds (300') jusqu'au point de départ, ('edit terrain ('tant borne comme suit: ouest, par le chemin publie; est.nord et sud.par le résidu dudit lot Xo 152 restant la propriété du vendeur.Avec bâtisses.» Pour être vendu ù la porte de l'église «les Saints-M art vrs-( 'anadiciis de Ycnisc-en-Quéhcc.dans le district de Bedford, le TRENTE ET UNIÈME jour de MAI 1966.Le Député.shérif.Bureau du Shérif.Avro\\i\\ Ilot u ans a.Palais de Justice, gweetsburg, P.Q.ce il avril 1966.1479S-lli-2-o point ; thence toward the south, at right angle and parallel with the said public road, a distance of one hundred feet (lOO'j up to a point; thence toward the west at right angle, a distance ol three hundred feet (300') up to the starting point.The said terrain being bounded as follow west, by the public road: east, north and south, by the residue of the said lot No.152 remaining the property of the vendor.With building-.\" To be soldat the church doorof Saints-Martyr- Canadiens of Venise-en-Québec, in the district < f Bedford, on THIRTY-FIRST day (d MAN 1966.AvroMS BOIHtASBA, Sheriff's office.Oeputy'Sheriff.Court House.Sweetsburg.P.Q., April U.1966.14798-16-2 C HICOUTIMI CHICOUTIMI Fieri Facias District de Chicoutimi Cour Supérieure, ( T A BANQUE ROYALE No 37,330.< -L» DU CANADA, corpora-I tion légalement constituée ayant une place d'affaires au numéro 15 de la rue Stc-Famille à Kénogami, district de Chicoutimi, demanderesse, vs ANTOINE CARON, domicilié et résidant au numéro 508 de la rue St-Pierre à Jonquière, district de Chicoutimi, défendeur et LEONID AS GAGNON et O.MER LAPOINTE, domiciliés et résidant en les cité et district de Chicoutimi, régistrateurs de la division d'enregistrement de Chicoutimi, district de Chicoutimi, mis en cause.« Un lopin de terre ou emplacement connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Jonquière, comme étant, d'après une certaine subdivision, le lot numéro vingt-six-A-cent quarante-huit du rang quatre (No 26-A-14S rang IV) dudit canton, lequel terrain mesure cinquante pieds (50') de largeur du nord-est au sud-ouest sur une profondeur de cent pieds (100') au nord-ouest au sud-est, et est borné au nord-est par le terrain de Jean-Paul Tremblay, au nord-ouest et au sud-ouest par le terrain de Joseph-Emile Brassard, et au sud-est par la route régionale Chicoutimi-Jonquière, le tout avec ensemble toutes les bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.» Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale Ste-Marie à Jonquière, le QUATRIEME jour du mois de MAI 1966, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du shérif, René Delisle.Chicoutimi, le 23 mars 1966.14514-13-2-o Fieri Facias District de Chicoutimi Cour Supérieure.i ALGONQUIN CAPITAL No 37.534.j CORPORATION LI- \u2022 MITED.corporation légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au numéro 10 Place Octave Créma/ie Ouest à Montréal, «listrict de Montréal, demanderesse, /.v CHARLES EUGÈNE BOILIANNE.ajusteur mécanicien, domicilié et résidant au numéro 584.rue Blough.à Arvida, «listrict «le Chicoutimi, défendeur et LÉONIDAS GAGNON «¦t OMER LAPOINTE.tous deux domiciliés et Fieri Facias District of Chicoutimi Superior Court, (THE ROYAL BANK Ol No.37,330.< L CANADA, body legally ' incorporated, having a place of business at numlicr 15 Ste-Famille St., in Kénogami, district of Chicoutimi, plaintiff, tw ANTOINE CARON, domiciled and residing at number 508 St-Pierre St., in Jonquière, district of Chicoutimi, defendant, and LEONIDAS GAGNON and OMER LAPOINTE, domiciled and residing in the city and «listrict of Chicoutimi, registrars of the registry division of Chicoutimi, district of Chicoutimi, mis-en-cause.\"A lot of land or emplacement known and designated on the official plan and in the book of reference of the cadastre of the township of Jonquière, as being, according to a certain subdivision, lot number twenty-six-A-one hundred and forty-eight on range four (No.26-A-l IS range IV) in the sai«l township, which lot of land measures fifty feet (50') in width from northeast to southwest, by a depth of one hundred feet (100') from northwest to southeast, and is bounded on the northeast by the terrain belonging to Jean-Paul Tremblay, on the northwest and southwest by the lan«l of Joseph-Emile Brassard, and on the southeast by the Chicoutimi-Jonquière regional highway; the whole together with all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.\" To be sold at the parochial church door of Ste-Marie in Jonquière, on the FOURTH day of the month of MAY, 1966, at THREE o'clock in the afternoon.René Delisle, Sheriff's Office, Sheriff.Chicoutimi, March 23, 1966.14514-13-2 Fieri Facias District «>f Chicoutimi Superior Court, t ALGONQUIN CAPITAL No.37.534.< CORPORATION II ' MITED, body legally incorporated, having its main place of business al number 10 Place Octave Crémazie West, ill Montreal, district of Montreal, plaintiff.CHAULES EUGENE BOILIANNE.media-nical adjuster, domiciled ami rediding at number 584 Blough St.in Arvida, district of Chicoutimi, defendant, ami LEONID AS GAGNON ami OMEB LAPOINTE, both domiciled and residing QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 88, 1988, Vol.98, No, 18 237:» résidant en let cité el diitrict «le Chicoutimi, rcgistrateurs du bureau d'enregistrement de < hicoutimi, mis-en-cause.« Toute cette partie sud-est du lot connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de la cité d'Arvida.comme étant la subdivision numéro f Chicoutimi, registrars of the registry oflice in Chicoutimi.mw-en-CSUie.\"All the south-east part of the lot known and designated on the official plan and in the book «>f reference of the city of Arvida.as being subdivision number ninety-nine <>f original lot number twelve (12-00).situate«l «m the southwest side of Blough Street, irregular in shape, bounded on the north-east hy subdivision forty-One of original lot number twelve (No.12-41).Blough St.).on the south-east by subdivision number one hundred of original lot number twelve (No.12-100) Stakes St.).on the southwest by part «>f subdivision number ninety-nine of original lot number twelve (P.12-00) which is the property «>f the Christian Brethren Church, «>n the north-west by the part of subdivision number ninety-nine of original lot number twelve (12-00) which is the property of .Mean, measuring fifty-eight and forty-hundredths feet (58.40') along the curve line formed by Blough St.on the one part, fifteen and twenty-four hundredths feet (15.21') along the straight line and on the Other part, fifty-seven and fifty-hundredths feet (57.50') along the curve line, which two lines are formed by Sickes St.seventy-three f«'«'t (73') along the straight line formed by the rear of the said lot, ninety-three and three-hundredths feet (93.03') along the straight line on the north-west side and having an area of approximately five thousand ninety-eight square feet (5,006 sq.ft.).Th«' said property as it is presently to Im* found, with the south-east half (S.-E.n{ ,'u' semi-detached house thereon erected, hearing number 584 Blough St.in the city «»f Arvida.with all tile rights, circumstances and dependencies attached thereto, without any reservation, and subject tt» all the active and passive servitudes, apparent or UnSpparenl which may affect it.and especially all the charges, conditions and obligations imposed in a deed «>f sale consented l«t by Leslie R.-Russell in favour of Aluminium Company of Camilla Limited, as it appears on a deed drawn up by the notary Roland Huot on the fourteenth «lay of .lune, one thousand nine hundred and fifty-five, under number 1400 of his minute-, and registered iu Chicoutimi on the twenty-seventh day of June of the same year, under number 120.475.and also a deed of amendment drawn up by notary Roland Huot OU the twenty-eighth day of October, one thousand nine hundred and fifty-seven under number 3159 of bis minutes, and registere«l in Chicoutimi on the seventh day of November of the same year, umler number 142.664.\" To Ik* sold at the parochial church door of Ste-Thérèse in Arvida.on the TWENTY-FIFTH «lay of the month of MAY.1000.at THREE o'clock in the afternoon.Ri:\\i: Dki.islk.Sheriff's Office.Sheriff.Chicoutimi.April 15.1900.14801-16-2 II ILL Canada Province «'f Quebec District Of Hull Superior Court, i /\"\\RVILLH PETTAPIECE No.S375 \\ ^'gentleman, of the city and ' district of Hull, province of 2370 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, avril i960, OS' année, n\" Hi de Québec, demandeur, m LES ENTREPRISES DICAIRE LIMITED, compagnie constituée on corporation dans In province il'Ontorin, uyunt su principale place d'affalrea à Orléans, Ontario, défenderesse \u2022 « Une propriété immobilière portant le numéro civique 75, me Boucherville, en la cité de Hull, connue et décrite aux plan et livre de renvoi officiels pour le quartier un de la cité de Hull, comme étant composée de: a) Subdivision numéro deux cent trente-sept du lot originaire deux cent cinquante-cinq; M Les quatre pieds sud-est de la subdivision ileux cent trente-huit dudit lot originaire deux cent cinquante-cinq (255-237.Ptie 255-2238, O I).mesurant mesure anglaise et plus OU moins quatre pieds (-!') de largeur sur ladite rue Boucherville et à l'arrière par une profondeur de quatre-vingt-douze pieds (92') et bornée comme suit: vers le nord-est par ladite rue Boucherville.vers le sud-est par ladite subdivision deux cent trente-sept dudit lot originaire deux cent cin-quante-Clliq, vers le sud-ouest, par partie de la subdivision mille deux cent dix-huit du lot originaire deux cent cinquante-cin<| (Ptie 255-12IS.O 1) (sentier) et vers le nord-ouest par le résidu de ladite subdivision deux cent trente-huit (res.256-288, O 1).Avec toutes les bâtisses dessus érigées, membres et appartenances.Avis et sujet à une servitude mutuelle de vue et de droit de passage en faveur et contre la propriété adjointe (lot Ptie 285-238) tel qu'il appert «l'un acte de servitude entre AI.Raymond De-celles et Dame Freda Lyon, épouse de Me Claude Blain.notaire cl al exécuté «levant Me Wilfrid St.Amond, notaire à Hull, le Hi juillet, 1062, dont copie a été enregistrée à Hull BOUS le numéro 140-852.Pour être vendus « en bloc .à mon bureau.au Palais «le Justice, en la cité «le Hull, le VINGT-CINQUIÈME jour de MAI 1966, à TROIS heures «le l'après-midi.Le Shérif.Bureau du Shérif.R.St-Piihuk.Hull ce 18 avril 1900.14797-16-2 Quebec, plaintiff es LES ENTREPRISES Db CAIRE LIMITKD.a company incorporated in the province of Ontario, having its principal place of business at Orléans, Ontario, défendant, \" An immoveable property bearing civic number 75 Boucherville Street, in the city of Hull, known and described upon the «tflicial plan and book of reference for ward one of the city of Hull, as being composed «»f : (a) Subdivision number two hundred and thirty-seven of the original lot two hundred and fifty-five: (/;) The four southeast feet «>f subdivision two hundred and thirty-eight «»f the said original loi two hundred and fifty-five (255-237.Pt.255-238, W 1).measuring English measure and more or less, four feet (4') in width on the said Boucherville Street and at the back by a depth of ninety - two feet (92') and bounded as follows: toward-the northeast by the said Boucherville Street, towards the southeast by the said subdivision two hundred and thirty-seven of the said original lot two hundred and fifty-five, towards the southwest, by part of subdivision one thousand two hundred and eighteen of the original loi two hundred and fifty five (Pt.266-1218, W 1) (Laneway) and towards the northwest by the residue of the said subdivision two hundred anil thirty-eight (res.255-23S.W 1).With all buildings thereon erected, member* and appurtenances.With and subject to a mutual servitude of view ami of right «)f way iu favour ami against the adjoining property (Lot Pt.255-238) as il appears from a deed of servitude between Mr.Raymond Decelles and Dame Freda Lyon wife of Me.Claude Blain, notary et al executed before Ale.Wilfrhl St.Anund.Notary at Hull, oil July lb 1902.of which a copy was registered in Hull under number 140-852.* To be sold \"en bloc\", at my oflice.at the Court House, in the city of Hull,the TWENTY-FIVE «lay of MAY, 1900.at THREE o'clock in the afternoon.R.St-Pii:kki:.Sheriff's Office, Sheriff.Hull April 18, 1966.14797-10-2-n KAMOURASKA Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province «le Québec District «le Kamouraska Cour Supérieure (T \"«OFFICE DU CREDIT «le Kamouraska.J ^ AGRICOLE DU QUÊ-No 25-274.| BEC, corps politique et in-' COipoié avant siège social à Québec, demandeur, rs GONZAGUE BELZILE.cultivateur «le Stc-Françoise.comté «le Rivièrc-du-Loup, P.Q., défendeur.Pour être vendus « en bloc » le: immeubles suivant' : « Une terre *itué\"C au premier rang «le la paroisse «le Ste-Fran«;oise, contenant quatre arpents «le front sur environ quarante-deux arpents «le profondeur, maintenant connue et désignée aux plan et livre de renvoi officiels «lu cadastre pour la paroisse de Ste-Françoise, sous 'es numéros quatre-vingt-onze, «piatro-vingt-«louze, «piatrc-vingt-quatorzc et «piatre-vingt-quinze (91, 92, 94 et 95), avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, .\u2022auf ù distraire du lot numéro quatre-vingt-«piatorzc le morceau Vendu à la Corporation K A AI O U II A S K A Fieri Facias f Ste-Francoise, county of Rivière-dii-Loup, P.Q., defendant.The following immovable!-, to Ik- sold \"en bloc\": \"A faun situated on the first range in the parish of Stc-Fran«;oi>e, mcasuiing four arpents in front by approximately forty-two arpents in depth, now known ami designated on the official plan and iu the lunik of reference of the cadaster for the parish of Sm-Françoise under number* ninety-one, ninety-two, ninety-four ami ninety five (91, 92, 94 and 95), with all the buildings thereon constructed, circumstances and dependencies.Save to Ik* withdrawn from lot number ninety-four is the piece of land sol«l to the School Corporation of Ste-Francoise for a school empla- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April $9, I'.HKi, Vol.US, No.Hi 2377 Scolftin?de Ste-Fnuieoi>e pour emplacement, de l'école, ainsi que la li>ière «le terrain vendue à Hector Rioux.près «lu petit lac au tïonteau nord de la terre at faisant partie des lots «juatre-vingl-diizc et quatre-vingt-«piatorze suivant, titre enregistré sous le numéro 897t>4.Sujet aussi à la scrvitmle «le passage pour ligne «le transmission électrique de La Compagnie «le Pouvoir «lu Has St-Laurent sur les lots numéros quatre-vingt-onze et «|Uatre-vingt-douze (91 et 92) dudit cadastre, suivant servitude enregistrée sous le numéro 7743(1.» Pour être vendus à la porte de l'église de Ste-Françoise, comté «le Rivière-du-Loup, le DOUZIEME jour «le MAI 1966, à DEUX heures de l'après-nmli.Le Shérif, bureau du Slmrif, MAURICE MoRIN.Itivière-du-Loup.08 2S mars 1066.14ôôl -13-2-0 [Première insertion: le 2 avril 1966] MÉGANTIC Canada \u2014 Province de Québec District de Mégantic ( our Supérieure, ( '\"PRE FF LÉ VEILLEUX, C.S.4489.«j *¦ cultivateur de St-Ben-' jannn, district «le Beauce, demandeur, vs DANIEL GAUYIN, commerçant de Sacré-Coeur de Alarie, district «le Alégantic, défendeur.1.« Un morceau de terrain connu et «lésigné comme étant les trois arpents nor«l-est du lot numéro «lix-neuf-A (Ptie.19-A) au cadastre offi-ciel pour le neuvième rang «lu canton de Tbet-ford, avec toutes les bâtisses «lessus construites, circonstances et dépendances.» 2.« Un morceau de terrain contenant cintjuan-le acres en superficie, plus ou moins, et sans garantie «le mesure précise, connu et désigné comme étant une partie du lot numéro dix-huit-B (Ptie.18-B) du neuvième rang du cadastre officiel de Thetford, et étant borné comme suit, savoir; d'un côté à Philemon Fontaine et de l'autre côté à Thomas Turcotte, le tout ou représentants, avec toutes les bâtisses dessus c«>nstruites, circonstances et tlépendances.» 3.« Un morceau «le terrain contenant cinquante acres en superficie, plus ou moins, connu et désigné comme étant une partie «lu lot numéro dix-huit-B (Ptie.18-B.) du neuvième rang du eadastre officiel du Canton de Thetford, et étant horné comme suit, savoir; des deux l>outs par les lignes rectangulaires dudit rang, d'un côté par une autre partie «lu même lot étant le morceau de terrain ci-dessus désigné, et de l'autre côté; à Thomas Lagueux ou représentants, avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances ».Sauf et à distraire «lu morceau de terrain ci-dessus décrit en troisième lieu; Un emplacement mesurant en mesures anglaises deux cents pieds de largeur par deux cents pic«ls de profondeur, connu et désigné comme étant une partie «lu lot numéro dix-huit-B (Ptie.18-B) du neuvième rang du Cadastre offi-ciel «lu canton de Thetford, et étant borné comme suit, savoir; en front par le chemin public, en arrière et deux côtés par le résidu dudit morceau de terrain, avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et.dépendances».«\u2022émeut, as well as the .-11 i j > oun «listrict of Beauce, plaintiff, S* DANIEL GAUVIN, trader, of Sacré-Coeur de Marie, district of Mégantic, defendant 1.\"A piece of land known and designated as being the three north-east arpents «>f lot number nineteen-A (P.19-A) in the official eeadasterof ninth Range in the township of Thetford, with all the buildings, thereon constructed, circumstances and dependencies.\" 2.\"A piece of land having an area of fifty acres, more or less, and without any guarantee of exact measure, known ami designated as being a part of lot number eighteen-B (P.18-B) on the ninth Range in the official cadaster of the township of Thetford, ami being bounded as follows, to wit: on one side by Philemon Fontaine and on the other side by Thomas Turcotte, the whole or representatives, with all the buildings thereon constructed, circumstances and depen-«lencies.\" 3.\"A piece of land having an area of fifty acres, more or less, known and designated as being a part of lot number eigbteen-B (P.18-B) on the ninth Range in the official dadaster of the township of Thetford, and being bounded as follows, to wit: on both ends by the rectangular lines of the said range, on one side by another part of the same lot l>eing the piece of lan«l designated above, and on the other side by Thomas Lajueux or representatives, with all the buildings thereon constructed, circumstances and dependencies.\" Save and to be withdrawn from the lot of land described above in the third place: An emplacement measuring, in English measure, two hundred feet in width by two hundred feet in depth, known and designated as being a part of lot number eighteen-B (P.18-B) on the ninth Range in the official cadaster of the township of Thetford, ami being bounded as follows, to wit: in front by the public road, in the rear and on both sides by the remaintlcr of the said lot of land, with all the buildings thereon constructed, circumstances and dependencies.\" 2378 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 99 avril ma, 98* année, «\u2022 ig Xon compris dans la présente vente le droit de coupe du boil mou vendu â Philippe Roy, commerçant, de Thctford-Mincs, par convention sous seing privé, avec une période «le trois années à compter «les présentes pour exercer tel droit.Il est par les présentes constitué contre remplacement ci-dessus distrait et réservé en faveur de Hennenégilde Jacques, au profit de l'immeuble présentement vendu, soit les trois morceaux de terrain ci-dessus désignés, une servitude perpé-tuelle de passage, pour tous genres de locomotion à être exercée sans frais sur le passage servant d'entrée, «le manière à permettre l'accès à l'immeuble présentement vendu jusqu'à la voie publique.Pour être vendus à la porte de l'église paroissiale de Sacré-Coeur de Marie, comté et «listrict judiciaire «le Mégantic, le MARDI DIX MAI, mil neuf cent soixante-six.à DEUX heures de l'après-midi.District «le Mt'-gantic.Le Shérif, 14552-13-2-o Denis Guénette.M 0 N T M A (i X Y De Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montmagny Bref d'exécution, ( T A CAISSE POPULAIRE Xo 10,795.!-L» DESJARDINS PA-iROISSIALE DE ST-MA-GLOIRE, caisse d'épargne et de crédit, ayant son siège social à St-Magloire, dans le comté de Bellechasse.demanderesse, et AI.FERXAXD LAYERDIÈRE, hôtelier et restaurateur, demeurant à St-Magloire, comté de Bellechasse.défemleur.« Un emplacement «lans le village «le St-Magloire, contenant soixante pieds «le largeur par un arpent «le profondeur plus ou moins désigné comme faisant partie du lot numéro cinquante-trois A (Ptie 53A) du catlastre officiel pour le rang nord-est, chemin Alailloux, Canton Roux, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances et borné en front au sud-ouest par le Chemin Royal, au nord-ouest par (îé«léon Lapointe, au nord-est par Hermé-négihle Cliampagne et au sud-est par Gilles Labrie ou ayants-droits, tel que le tout se trouve actuellement avec les servitudes, actifs et passifs.Pour être vendu à la jiorte de l'église de St-Magloire, comté de Bellechasse, MARDI, le VINGT-QUATRIÈME jour de MAI mil neuf cent soixante-six à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, JbaN-PauL Tkmmblay.Montmagny, 10 avril I960.14774-10-2-o M 0 N T R É A L Not included in the present sale is the right t<> «\u2022ut soft-wood sold to Philippe Roy, trader, of Thctford-Mines, by agreement under private seal, to exercise said right over a period of three years from ami after these presents.A perpetual servitude of right of way for id I types of transportation which may be used without cost on the right of way used as an entrance, in such a way as to grant access to the immovable presently sold from the public road, is hereby constituted on the above-withdrawn and reserved emplacement in favour of Hennenégilde Jacques, to the profit of the immovable presently sold, that is, the three pieces of land designated above, To be sold at the parochial church door <>f Sacré-Coeur de Marie, county and judicial district of Mégantic, on TUESDAY, the TENTH day of MAY, one thousand nine hundred and sixty-six, at TWO o'clock in the afternoon.District of Mégantic.Demie Gubmbttb, 11552-13-2 Sheriff.MONT M A G X Y De Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec Superior Court \u2014 District of Montmagny Writ of Execution ( T A CAISSE POPULAIRE Xo.10,795.\\ La DESJARDINS PA l ROISSIALE DE ST-MAGLOIRE, a savings and credit union, having it -head oflice at St-AIagloire, in the county of Bellechasse, plaintiff, vs AI.FERN AND LA-YERDIÈRE, hotel keejK'r ami restaurateur, residing at St-Magloiie, county of Bellechasse.defendant.\"An emplacement in the village of St-Magloire, containing sixty feet in width by «me arpent in depth, more or less, designated as being part of lot number fifty-three A (Pt 53A) of the official cadaster for the northeast range, Alailloux road.Roux township, with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies, and bounded in front on the southwest by the Highway, on the northwest by Gédéon Lapointe, on the northeast by Hennenégilde Champagne and on the southeast by Gilles Labrie or Ixmeficiaries, such as the whole appears presently with the servitudes, active and passive.To be sold at the church door of St-AIagloirc.county of Bellechasse, TUESDAY, the TWENTY-FOURTH day of MAY one thousand nine hundred and sixty-six at THREE o'clock in the afternoon.Jean-Paul Tebmblat, Sheriff's Office, Sheriff.Montmagny, April 16, 1966.14774-16-2 AI O NTRÉ A L Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Alontréal Montréal, à savoir: ( ARMAND RIEN -No 665 432.< -**-DEAU, demandeur, si l GUY COURTEAU, défendeur.« Ce certain emplacement ayant front sur la 85e Avenue, dans la cité de Chomedey, mesurant Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Alontreal, to wit : { A RM AND RIEN-No665 432.{AdEAU, plaintifî, l vs GUY COURTEAU, de-fendant.\"That certain emplacement fronting on 86th Avenue, in the city of Chomedey, measuring QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, April 98, 1988, Vê, 98, Ate, 18 237!) cinquante pieds (50') de lurgeur par cent cinquante-huit pieds et cinq dixièmes de pied (158.5') de profondeur et étant connu et désigné comme le lot numéro deux cent quatre-vingt-sept de la subdivision du lot originaire numéro quatre-vingt-quatorze (04-287) aux plan et livre Je renvoi officiels de la paroisse de St-Martin.Avec le chalet dessus érigé portant le numéro civique 430, 85e Avenue.» À être vendu à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de St-Alaxime (dans la cité de ( homcdey), maintenant cité «le Laval, le SIXIEME jour du mois de MAI 1900, à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif, bureau du Shérif, Bernard Sarrazin, en.Montréal, 28 mars I960.14553-13-2 NICOLE T fifty feet (50') in width by one hundred and fifty-eight feet and five-tenths of a foot (158.5') in depth ami being known and designated as lot number two hundred and eighty-seven of the subdivision of original lot number ninety-four (94-287) on the official plan and book of reference of the parish of St.Martin.With the bungalow dwelling thereon erected l>earing civic number 430, 85th Avenue.\" To be sold at the parochial church door of the parish of St-Maxime (in the city of Chomedey), now City of Laval, on the SIXTH day of the month of AIAY 1000, at ELEVEN o'clock in the morning.Bbbnaed Sarrazin, q.c, Sheriffs Office, Sheriff.Montreal, March 28, 1900.14553-13-2-o N I COLET Fieri Facias Canada \u2014 Province de Québec District «le Nicolet ( 'our Supérieure.1 T ^OFFICE DC CREDIT No 3105.j -L» AGRICOLE DU QUÊ- V BEC, corps poli i ique et incorporé, avant siège social à Québec, demandeur, vs M.JEAN-JACQUES DEAIERS.cultivateur «le Ste-Cécile de Lévrard, comté de Nicolet, «lé-Fendeur.« Une terre située sur le quatrième rang «le la Seigneurie de Lévrard, en la paroisse «le Stc-( ccile de Lévrard, mesurant environ trois arpents de largeur au front par environ trente arpents de profondeur, plus OU moins et sans garantie de mesure précise, connue et désignée au cadastre «le la paroisse «le St-Pierre les Bccqucts, comprenant Ste-Cécile «le Lévrard comme étant les lots numéros quatre cent cinquante et un et quatre cent cinquautc-deux (451 et 452).avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu (en bloc), à lu porte de l'église paroissiale «le Ste-Cécile «le Lévrard.le VINGT-CINQUIÈME jour de MAI 1966, à ONZE heures «le l'avant-midi.Le Shérif.bureau «lu Shérif, georges Doi/cet.Nicolet, ce 14 avril 1000.14796-16-2-0 Fieri Facias Canada \u2014Province of Quebec District of Nicolet Superior ( '«mil, ( T H E Q1 \" E B E ( ' F A R AI No.3105.CREDIT BUREAU, ' body iM)litic ami corporate, having its head oflice in Quebec, plaintiff, si Mr.JEAN-JACQUES DEAIERS, l'armer «>f Ste-Cécile de Lévrard, county «>f Nicolet, defendant.\"A farm situated on the fourth range in the Seigniory «>f Lévrard, in the parish of Ste-Cécile «le Lévrard, measuring approximately three arpents in width in front by approximately thirty arpents in depth, more or less, and without any guarantee of exact measure, known and designated in the cadaster of the parish of St-Pierre les Bccqucts, comprising Ste-Cécile de Lévrard, as being lots numbers four hundred and fifty-one ami four hundred ami fifty-two (451 and 452); with the buildings thereon constructed, circumstances ami dependencies.\" To be sold \"en bloc\" at the parochial church r of Ste-Cécile de Lévrard, on the TWENTY-FIFTH «lay of MAY, 1000.at ELEVEN o'clock in the forenoon.Georges Doucet, Sheriff's Office, Sheriff.Nicolet, April 14, 1966.14700-10-2 QUÉBEC Fieri Facias l )uébec à savoir :/ A LB ERIC N O R E A U Cour Supérieure j \u2022**» INC.corporation lé- No 142-923.\\ gaiement constituée ayant \\ son siège social à Québec, district se Québec, contre JEAN BARNABE, de Québec, «listrict «le Québec et EDOUARD VERREAULT, es-qualité «le rt:gistratcur.«le Chateau-Richer, «listrict de Québec, et J.C.PICHER, es-qualité de régistrateur, du district de Québec, mis-en-cause.« A.\u2014 La subdivision six (0) «lu lot numéro Irente-huit (38) au cadastre officiel «le Ste-Origitte «le Laval.B.\u2014 La subdivision soixante (60) «lu lot numéro quinze cent quarante-trois (1543) au cadastre officiel «le Bcauport.Avec bâtisse dessus construite.» Pour être vendu à la porte «le l'église de Ste* Brigitte «le Laval, comté de Montmorency, le QUÉB EC Fieri Facias Quebec.l«) wit : i A LB ERIC N 0 R E AU Superior Court.J *1* INC.btxly legally in-No.142-923.j corporaled, having its head ' office in Quebec, «listrict of Quebec* versus JEAN BARNABE, of Quebec, district of Quebec, ami EDOUARD VERREAULT, in his capacity as registrar, of Chateau-Richer, district of Quebec, and J.C.PICHER.in his capacity as registrar of the «listrict of Quebec, mis-cn-causc.\"A.\u2014 Subdivision six (0) of lot number thirty-eight (38) of the official cadaster of Ste-Brigiltc de Laval.B.\u2014 Subdivision sixty (00) of lot number one thousand five hundred ami forty-three (1543) in the official cadaster «>f Beauport.With the building thereon constructed.\" To be sold at the church «loor «>f Ste-Brigitte de Laval, county of M«)iitmorency.on the 2380 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril 1900, 93' année, n\" 10 VINGT-SEPTIÈME jour de MAI prochain à DIX heures de l'avant-midi.Le Député-Shérif, Bureau du Shérif.Ai.heut F.R a cette.Québec, le 15 avril 1966.14817-16-2-0 [Première insertion: 23 avril 190(5.) (Deuxième insertion: 14 mai 1900.Fieri Facias Québec, è savoir: i TfOLOSTAT II FAIT NG Cour Supérieure, 1 SYSTEMS LIMITED, Xo 128-225.) corps politicpie et incorporé.' dûment constitué comme tel, avant son siège social et principale place d'affaires en les ville et district de Montréal, vs C.JOBIN LIMITÉE, corps politique et incorporé, dûment constitué comme tel, ayant son siège social et principale place d'affaires dans le district de Québec, et PAUL G INGRAS ET MAURICE DE COSTER, en leur qualité de syndics conjoints dans la faillite de la défenderesse, CENTRE COMMERCIAL LEVIS IXC.corps politique et incorporé dûment constitué comme tel ayant son siège social et principale place d'affaires à la Place Youville, district de Québec, et JULES CARRIER, en sa qualité de regis-trateur du Bureau d'Enregistrement, pour la division d'enregistrement de Lévis, mis-en-cause.« I.u) Partie du lot quarante-huit (Ptie 4M du cadastre officiel pour la paroisse de Notre-Dame de la Victoire, comté de Levis, de figure irrégulière, bornée au nonl-est par la Route Xo23, Lévis-Jaekman.au sud-est par la Route militaire abandonnée, au sud-ouest par les lots 47-1 et 47-2 et au nord-ouest par ledit lot 47-2; b) La subdivision numéro un du lot quarante-sept (47-1) dudit cadastre, de figure quadrilatérale, bornée vers le nord-est par ledit lot numéro 48, vers le sud-est par ladite Route militaire, vers le sud-ouest par la partie non subdivisée du lot 47 et vers le nord-ouest par le lot 47-2; e) La subdivision deux dudit lot quarante-sept (47-2) de figure irrégulière, bornée au nord-est en partie par la Route numéro 23 et en partie par lot 48, au sud-est par les lots 4S et 47-1 et au sud-ouest et au nord-ouest par le lot 47; Ia?tout formant un emplacement mesurant cent cinquante-deux pieds et deux dixièmes (152.2') au nord-est sur la Route numéro 23, cinquante-cinq pieds (55') au sud-est sur l'ancienne Route militaire, cent trente-six pieds (130') au sud-ouest et quatre-vingt-onze pieds et six dixièmes (91.0') au nord-ouest, le tout plus ou moins, mesure anglaise; II.Un certain terrain composé «l'une partie du lot mille deux cent vingt et un (Ptie 1221) «lu cadastre officiel pour le Quartier Notre-Dame, cité «le Lévis, et «le parties «les lots «piarante-sept.«piarante-neuf et cinquante (Ptics 47, 49 et 50) et «les lots quarante-neuf-deux et cinquante-vingt-deux (Lots 49-2 et 50-22) du cadastre officiel pour la paroisse de Notre-Dame «le la Victoire, comté «le Levis, les lots «lu dernier cadastre faisant partie actuellement de la cité de Lévis, Quartier Villemay.( 'e terrain est «le figure irrégulière, borné vers le nonl-est par une partie dmlit lot 47, la Route St-Henri et les lots 47-2 et 47-1, «le la paroisse «le Notre-Dame de la Victoire, vers le sua-est par la Route St-Henri les lots 47-2.03-1, (52-1 et 50-25 de ce dernier cadastre, vers le sud-ouest par les lots 50-15.50-14.50-13, 50-12, 50-11.50-10 et 50-23 «le ce dernier ca«lastre, vers le nord-ouest par le lot 50-23, parties des lots 50.49 et 47 «le la TWENTY-SEVENTH «lay of MAY next al TEN o'clock in the forenoon.Aluekt F.Racette.Sheriff's Office, Deputi/Sheriff.Quebec.April 15, 1900.14817-16-2 [First insertion: April 23, 1900.J I Second insertion: May 14, 1900.) Fieri Facias Quebec to wit: ( V OLOSTAT H EAT IN*.Superior Court) ^ SYSTEMS LIMITED, n No.12S-225.\\ body politic and corporate, duly ' incorporated as such, having its head office ami principal place of business in the city ami district of Montreal vs C JORI.N LIMITÉE, a boby politic ami corporate, duly incorporated as such, huviug its head oflice and principal place of business in the district of Quebec, and PAUL GINGRAS AND M AU RICK DE COSTER, in their quality as joint Trustee* in the Bankruptcy of defendant, CENTRE COMMERCIAL LEVIS INC.a body politic and corporate, duly incorporated as such having ii- head office ami principal place of business, in Youville Place, district «>f Quebec, and JULES CARRIER, in his quality as registrar of the Registry oflice.for the Registration division of Levis, mis-en-cause.I.(a) Part of lot forty-eight (Pt.48) of the official cadastre «if the parish of Notrc-Danu de la Victoire, county of Levis, of an irregular figure, bounded on the northeast by route No.23, Levis-Jackman, on the southeast by the abandoned Military route, on the south-west by lots 47-1 and 47-2 ami on the north west by said lot 47-2; (/») Subdivision number one of lot forty-seven (47-1) of the sai«l cadastre, «>f a quadrilateral figure, bounded on the northeast by said loi number 48, on the southeast by the sait! Military route, on the southwest by the unsubdivided part of lot 47 and on the northwest by lot 47-2: (c) Subdivision two «>f said lot forty-seven (47-2) of an irregular figure, bounded on the northeast in part by route number 23 and in part by lot 4S, on the southeast by lots 48 ami 47-1 ami on the southwest ami northwest by l«>t 47: The whole forming an emplacement measuring one hundred and fifty-two feet and two tenths (152.2') on the northeast by route number 23, fifty-five feet (55'), on the southeast by the former Military route, one hundred ami thirty-six feet (136), on the southwest ami ninety-one feet ami six tenths (91.6') on the northwest, the whole more or less, English measure; II.A certain piece of land composed «>f pari of lot one thousand two hundred and twenty* «>nc (Pt.1221) of the official cadastre for the Ward of Notre-Dame, city of Levis, ami of parts of lots forty-seven, forty-nine and fifty (Pts, 47.49 ami 50) ami lots forty-nine-two and fifty-twenty-two (Lots 49-2 ami 50-22) of the official cadastre of the Parish of Notre-Dame «le la Victoire, county of Levis, the lots of the lasl cadastre being presently part of the city of Levis.Ward of Villemay.This piece of land is of an irregular figure, bounded on the northeast by a part of said lot 47.St-Henri route and lots 47-2 and 47-1, of the parish of Notre-Dame de la Victoire, on the southeast by the route of St-Henri, lots 47-2.03-1, 62-1 and 50-25 of this last cadastre, on the southwest by lots 50-15, 50-14, 50-13, 50-12 50-11, 50-10 and 50-23 of this last cadastre, on the northwest by lot 50-23, part of lots 50.49 and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.April 23.1906, Vol, 08.No.16 2381 [NUfoiftae «le Notre-Dame «le la Victoire, Ct par partie du lot 1221 «lu Quartier Notre-Dame et vers l'ouest par ledit lot 1221, mesurant ledit emplacement cent quatre-vingt-un pieds et cinq dixlèmea (181.5') cent vingt pieds et quatre dixième! (120.4') et sept pieds et quatre dixièmes i7.4') sur la Itoute St-Henri au nord-est et au sud-est, quatre-vingt-onze pieds et six dixième! (01.6') et cent trente-neuf pieds et six dixième! ( 139.6') le long «les lots 47-1 et 47-2 au nord-est et au sud-est, cinq cent onse pieds (511') le long des lots 63-1, 02-1 et 50-26 au sutl-est.<|uatrc cent «pintrc-vingt-ipuitorze pieds (494') et soixan-te-quâtorxe pieds (74') au sud-ouest l«* long «les lots 50-15 à 50-10 et 50-23, quinte pieds (15') MUr le lot 50-23 au nord-OUest, trois cent soixante-trois pieds et quatre dixièmes (303.4') au nord ouest sur la ligne partageant parties «les l«>ts 47 «\u2022t 49.deux cent trente pieds et sept dixièmes 1230.7) au nonl-est sur lu ligne purtugeunt parties ¦ lu lot 47 (cette dernière ligne «'tant située à cent pieds au sud-ouest du mur du garage actuel), cent «piutre-vingt-onze pieds (191') au nonl-ouest sur la ligne partageant parties «les lots 47 et 1221 ¦cette dernière ligne «-tant située à soixante pieds au sud-est «lu mur «lu garage actuel) et soixante pieds et trois dixième! (00.3') à l'ouest sur la ligue partageant parties du lot 1221; contenant en superficie trois cent mille cinquante et un pieds carrés (300.051 p.e.) mesure angluise.Ix'«lit terrain test, tel qu'indiqué, contourné en jaune sur un plan prepare par Gérard Desjardins.a.o.le vingt-trois novembre 1959.dont copie est annexée au titre d'acquisition du présent vendeur.III.Un certain terrain de figure irrégulière, faisant purtie «les lots quarante-sept, quarante-neuf et cinquante (Pties 47, 49 et 50) «lu cadastre officiel «le In paroisse «le Notre-Dame «le la Victoire, cité «le Lévis, Quartier Villemay.comté et division «l'enregistrement «le Lévis; Lomé vers le nord-est par une partie «lu lot 47.vers le sud-est par une partie «les lots 47.40 et 50, propriété «le l\\ an line Cor])., vers le sud-OUest par une partie des lots 50 et 50-23 et vers le nor«l-oucst par le prolongement projeté «lu Boulevard Adélard parties «les lots 47.40 et 50) appartenant au vendeur «le Ivanhoe Corp.(LÔÛis Vachon); mesurant cent trente-huit gieds (1380 au nonl-est.trois cent soixante-trois pieds et quatre dixièmes (363.4') au suf Xotre-Dame «le la Victoire, ami by part of lot 1221 of the Ward «>f Xotre-Dame and on the west by said lot 1221, the said emplacement measuring one hundred ami eighty-one feet and five tenths (181.5') one hundred ami twenty feet and four tenths (120.4') and seven feet ami four tenths (7.4') on the route of St-Henri on the northeast and on the southeast, ninety-one feet and six tenths (91.6') ami one hundred and thirty-nine feet and six tenths (139.0') along lots 47-1 ami 47-2 on the northeast und southeast, five hundred and eleven feet (511') along lots 03-1.62-1 ami 50-25 on the southeast, four hundred and ninety-four feet (494') and seventy-four feet (74') on the southwest along l«>ts 50-15 to 60-10 and 50-23, fifteen feet (15') on lot 50-23 on the northwest, three hundred and sixty-three feet and four tenths (303.4') on the northwest on the line dividing parts of lots 47 and 49.two hundred and thirty feet and seven tenths (230.7') on the northeast on the line dividing parts «>f lot 47 (this latter line iiciiin situated at one hundred feet to the southwest «>f the wall of the present garage), one hundred ami ninety-one feet (191') on the northwest by the line dividing parts of lots 47 ami 1221 (this latter line being situated at sixty feet t«> the southeast of the wall of the present garage) ami sicty feet ami three tenths (00.3') on the west by the line dividing parts of lot 1221: containing in area three hundred thousand fifty-one square feet (300.051 sq.ft.) English measure.The said land is.such as indicated, traced in yellow on a plan prepared by Gérard Dcsjardins.US., on the twenty-third day of November, 1059.of which a copy is annexed to the acquisition deed of the present vendor.III.A certain piece «>f land «>f an irregular figure, being part of lots forty-seven, forty-nine and fifty (Pts.47.49 ami 50) of the official cadastre of the Parish of Xotre-Dame «le la Victoire, city of Levis, Ward of Villemay, county and registration division «>f Levis; bounded on the northeast by a part of lot 47, on the southeast by a part of lots 47.49 und 50, property of Ivanhoe Corp.on the southwest by u part of lots 50 ami 50-23 and on the northwest by the planned prolongation of Adélard Boulevard (part of lots 47.40 and 50) hchmging t«> the vendor of Ivanhoe Corp.(Louis Vachon); measuring one hundred ami thirty-eight feet (138') on the northeast, three hundred ami sixty-three feet ami four tenths (303.4') on the southeast, eighty-one feet ami four tenths (SI.4') on the southwest, and three hundred ami sixty-eight feet (368') on the northwest ami containing iu area thirty-nine thousand one hundred and fifteen square feet (39.115 sq.ft.) English measure.With buildings constructed thereon, circumstances and dependencies.\" To be sohl at the church door of Notre-Dame «le la Victoire, count v of Levis, on the TWENTY-SEVENTH day of next MAY.at TEN «>'c!ock in the morning.Ai.iikkt F.Racktti:.Sheriff's Office.Deputy-Sheriff.Quebec, April 19.1966.14820-16-2 [First insertion: April 23.1900.] [Second insertion: Alay 14.I960.] 2382 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril 1900, 98' année, n° 10 It O B E R V A L Fieri Facias (le Terris < 'auada \u2014 Province de Québec District de Roberval ('our Supérieure, ( \\/f ETROPOUTAN LIFE de Roberval, J 1VA INSURANCE COM-N'o 30,360.\\ PAN Y, corporation légale-' ment constituée, ayant une place d'affaires pour la province de Québec, en la cité de Montréal, (listrict de Montréal, demanderesse, vs YYON CASTONGUAY, domicilié et résidant au numéro 11, 3ième Rue, St-Félicien, district de Rol>erval, province de Quél>ee, défendeur.A vis de vente « Un terrain-emplacement, situé en la municipalité de la ville de St-Félicien, connu et désigné comme étant la subdivision trente-sept du lot originaire numéro quarante-huit-C (No 48-C-37), du troisième (III) rang, du cadastre officiel du canton Asbuapmouchouan, avec la maison dessus construite, appartenances et dé|>en(lances.» Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de la ville de St-Félicien, comté de Roberval, district de Rol>erval, le DEUXIÈME (2e) jour de JUIN, 1900, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Lkox-AIauhick Lavoik.Palais de Justice, Roberval, le 19 avril 1966.14SlS-lG-2-o S A G 1 E N A Y De Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Quebec District de Saguenay Cour de Magistrat, j ~E E R X A X 1) T R E M -No 18.328.-j -T BLAY.boulanger, do-' micilié à Raie St-Paul.comté de Charlevoix.Québec, demandeur.vs AURÊ-LIEN BOILY.domicilié à St-Urbain, comté de Charlevoix Québec, district de Saguenay.défendeur.« Un emplacement situé à St-Urbain.mesurant quarante-trois pieds de largeur sur soixante-douze pieds de profondeur, mesure anglaise, désigné comme étant composé d'une partie du lot numéro quatre cent quarante-sept (Ptie de 447) au cadastre officiel de la paroisse de St-Urbain.borné en front au sud par la route St-Jérôme, en profondeur, vers le nord et du côté ouest par le terrain du vendeur.Antonio Girard, sur ledit lot 447 et du côté est par remplacement d'Albert Rouchard.avec circonstances et dépendances.N.B.Ce même emplacement est maintenant connu sous le numéro quatre de subdivision du lot original quatre cent quarante-sept (447-4) qui se lit comme suit: « De figure irrégulière.Borné au nord-ouest pur le lot 447 n.s.; au nord-est par les lots 447 n.s., et 447-3; au sud-est par la route St-Jérôme.au sud-ouest par les lots 447-5 et 447 n.s.; mesurant soixante et un pieds et cinq dixièmes (61.5') au nord-ouest; soixante-neuf pieds ((59) au nord-est; cinquante-sept pieds et neuf dixièmes (57.9') au sud-est; et soixante-quinze pieds et trois dixièmes (75.3') au sud-ouest; contenant en superficie quatre mille, quatre cent soixante-dix-huit pieds carrés M.A.(4,478 p.e).Il O B E H V A L Fieri Facias de Terris ( 'auada \u2014 Province of Quebec District of Roberval Superior Court, ( XyfETROPOLTTAN LIFE of Roberval, ! AVI INSURANCE COM-Xo.30,350.\\ PANY, a corporation legally incorporated, having its place of business for the Province of Quebec, iu the eitv of Alontreal, district of Alontreal, plaint ill\", vs' YVON CASTONGUAY, domiciled and residing at number 11, 3rd Street, St-Félicien.district of Roberval, Province of Quebec, defendant.Notice of sale \"A terrain-emplacement, situated in the municipality of the town of St-Félicien, known and designated as being subdivision thirty-seven of original lot number forty-cight-C (Xo.48-C-37).of the third (III) range, of the official cadaster of the township of Asbuapmouchouan, with the house thereon erected, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the church door of the parish of the town of St-Félicien, county of Rolicrval.district of Roberval, on the SECOND (2) day of JUNE, 1000.at TWO o'clock in the afternoon Léon-Maurice Lavoik, Sheriff's Office, Sheriff.Court House, Roberval.April 19.1000.14818-10-2 S A G I E X A Y De Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Saguenay Magistrates Court.| \"C E R X AN I) T R E M Xo.18,328.\"j 1 BLAY.baker, domi-' ciled at Raie St-Paul.county of Charlevoix.Quebec, plaintiff.vs AURÉ-LIEN BOILY.domiciled at St-l'rbain, county of Charlevoix.Quebec, district of Saguenay.defendant.« An emplacement situated in St-Urbain measuring forty-three feet in width by seventy-two feet in depth, english measure, designated as being composed of a part of lot number four hundred and forty-seven (P.447) in the official cadaster of the parish of St-Urbain, hounded in front, on the south, by St-Jérôme road, in depth, on the north and on the west side by the land belonging to the vendor, Antonio Girard, on said lot 447 and on the east side by the emplacement belonging to Albert Bouchard, with cireumstann« and dependencies.N.B.This same emplacement is now known under number four of the subdivision of original lot four hundred and forty-seven (447-4) which roads as follows: \"Of irregular shape, bounded on the north-wesi by lot 447 n.s., on the north-east by lots 447 n.s.and 447-3.on the south-east by St-Jérôme road, on the suth-west by lot 447-5 and 447 n.s., measuring sixty-one and five-tenths feet (01.5') on the north-west, sixty-nine feet (09') on the north-east, fifty-seven and nine-tenths feel (57.9') on the south-east, and seventy-five and three-tenths feet (75.3') on the southwest, having an area of four thousand four hundred and seventy-eight square feet.E.M.(4.478 sq.ft.) QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, April H, I960, Vol.us, Mo.16 2383 lu terrain vacant mesurant quarante-trois piedl 'le largeur sur cinquante-quatre pieds de profondeur, mesure anglaise, désigné comme étant une partie centre-sud du lot numéro quatre cent quarante-sept, non subdivisé (Ptie C.S.447).n.s.) au cadastre officiel de la paroisse de St-l'rbain; borné en front vers le sud par le terrain de l'acquéreur.Aurélien Boily, (lot 447-4), en profondeur et du côté est par le terrain de Lucien Bouchard, sur ledit lot 447, n.s.et vers l'ouest par remplacement de Roméo McXicoll.» Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de St-l'rbuin.comté- de Charlevoix.JEUDI, le VINGT-SIXIÈME jour de MAI 1966 à DIX heures de l'avant-midi, Ia- Shérif.bureau du Shérif.SvLVtO TREMBLAY.La Malbaie, le 18avril 1066.1481946-2-0 S A I N T \u2014 F R A X Ç O I S Fieri Facias Je Terris District de St-François Cour Supérieure ( T ^OFFICE DE CRÉDIT ( Sherbrooke), ) AGRK 'OLE D U QU E- Xo 30.62S.\\ BEC, corps politique et in-' corporée, ayant soège social à Quélwc, demandeur, vs XOEL TURAIEL, autrefois cultivateur de St-Fortunat, comté de Wolfe, maintenant domicilié à 1381 est, rue Fleury, Montréal, défendeur.« Une terre située à St-Fortunat, comté do Wolfe, composée: a) De la moitié sud-est du lot numéro quatre s.e.4) du neuvième rang, au cadastre officiel du canton de Wolfestown, contenant cent acres de terre en superficie, plus ou moins, bornée du côté sud-est par le lot numéro cinq, du neuvième rang, au lx>ut sud-ouest par le cordon entre ies rangs neuf et dix, du côté nord-ouest par la demie nord-ouest dudit numéro quatre et au l>out nord-est par le numéro quatre B du huitième rang.h) D'un morceau de terre connu comme faisant partie du numéro quatre (Ptie 4), du rang neuf, au cadastre officiel du canton de Wolfestown, mesurant deux arpents et demi de largeur, plus ou moins, par la profondeur qu'il y a entre le chemin public, qui traverse ledit lot quatre, et le cordon du rang huit, dudit canton, borné au sud-est par la demie sud-est dudit numéro quatre, décrète à l'alinéa « a » ci-dessus, du côté nord-ouest par partie dudit numéro quatre vendue à Ludger Gosselin, au bout sud-ouest par le susdit chemin public, et au bout nord-est par le cordon dudit rang huit, avec circostances et dépendances.c) Du lot numéro quatre B (4-B) du huitième rang, au cadastre officiel du canton de Wolfestown, contenant environ cent acres de terre en superficie, plus ou moins, distraction faite dudit lot quatre B de l'emplacement appartenant aux Commissaires d'Écoles pour la municipalité de St-Fortunat, avec bâtisses et dépendances.Avec toutes les bâtisses construites sur les susdits terrains, circonstances et dépendances.Avec droit de passage sur ledit numéro quatre B du huitième rang dudit cadastre, en hiver seulement, en faveur des propriétaires de la partie du lot numéro trois, du neuvième rang dudit cadastre, située entre le chemin public qui traverse le neuvième rang et le cordon entre les huitième et « A vacant lot of land measuring forty-three feet in width by fifty-four feet in depth, english measure, designated as being a south-center part of lot number four hundred and forty-seven, unsubdivided (S.C.P.447.n.s.) in the official cadaster of the parish of St-Crbain.bounded in front, on the south, by the land belonging to the purchaser, Aurélien Roily (lot 447-4), in depth, and on the east side, by the land of Lucien Bouchard, on said lot 117 n.s.and on the west by the emplacement of Roméo McNieoil.\" To be sold at the church door of the parish of St-l'rbain, countv of Charlevoix, on THURSDAY, the TWENTY-SIXTH day of MAY, 1966, at TEX o'clock in the forenoon.Svlvio Tremblay, Sheriff's Oflice.Sheriff La Malbaie.April 18, 1966.14819-16-2 SAINT - FRANCIS Fieri Facias de Terris District of St.Franchi Superior Court ( THE QUEBEC FARAI (Sherbrooke), ) *¦ CREDIT BUREAU, a Xo.30,628.) l)ody politic and corporate, ' having its head office in Quelle, plaintiff, at NOEL TURMEL, formerly fanner of St-Fortunat, county of Wolfe, now domiciled at 1381 Fleury Street East, Montreal, defendant.\"A piece of land situated in St-Fortunat, county of Wolfe, composed: (a) Of the south-east half of lot number four (}A s.e.4) of the ninth range, on the official cadaster of the township of Wolfestown, containing in area, one hundred acres of land, more or less, hounded on the south-east side by lot number five of the ninth range, on the southwest end by the l>order between ranges nine and ten, on the north-west side by the north-west half of said number four and on the north-east end by number four B of the eighth range.(b) Of a piece of land known as being part of numl)er four (Pt.4), of the ninth range, on the official cadaster of the township of Wolfestown, measuring two arpents and a half in width, more or less, by the depth existing between the public road, which crosses said lot four, and the border of the eighth range of the said township, bounded on the south-east by the south-east half of said number four, described in the first line of paragraph \"a\" hereabove, on the north-west side by part of said number four sold to Ludger Gosselin.on the south-west end by the above-mentioned public road, and on the north-east end by the border of said eighth range, with circumstances and dependencies.(c) Of lot number four B (4-B) of the eight range, on the official cadaster of the township of Wolfestown, containing approximatively one hundred acres of land in area, more or less, distraction made from said lot four B of the emplacement l>elonging to the School Commissioners of the Alunicipality of St-Fortunat, with buildings and dependencies.With all the buildings constructed on the a!>ovc-mentioned lands, circumstances and dependencies.With the right of passage on said number four B of the eighth range of the said cadaster, in winter only, in favor of the proprietors of part of lot number three, from the ninth range or the said cadaster, situated between the public road which crosses 2884 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril 1960, 03' année.u° tù neuvième rangs, pour communiquer de cette partie du lot numéro trois, du neuvième rang, au chemin public entre les septième et huitième rangs du canton de Wolfestown.» Pour être vendus « en bloc » à la porte de l'église paroissiale de St-Fortunat, comté de Wolfe, MARDI, le TROISIÈME jour de MAI 1966, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Donat Jacques.Palais de Justice, Sherbrooke, ce 23 mars 1966.14540-13-2-o [Première insertion: le 2 avril 1966] SAINT \u2014 HYACINTHE Canada \u2014 \u2022 Province de Québec District de St-Hyacinthe ( TEAX III BERT, rentier et No 17,234.«jj PAUL DURANLEAU, t avocat, tous deux de la ville de Belceil, «listrict de Richelieu, demandeurs.vs MAURICE ROBITAILLE, de la ville de St-Hilaire.district «le St-Hyacinthe, défendeur.« Un emplacement situé au village de St-Hi-laire, connu et désigné sur le plan et livre «le renvoi officiels «le la paroi»se «le Sl-Hilaire.division de l'enregistrement «le Rouville, sous le numéro quatre «le la subdivision officielle du lot originaire numéro «pmtre-vingt-dou/.e (92-4) avec ensemble les batistes dessus érigées, à distraire cependant dudit lot, une lisière «le terre de «lix-sept pieds «le largeur, mesure anglaise, courant «lu nort-est au SUd-OUest, prise pour l'ouverture et la légation «l'une rue.de cinquante pieds «le largeur bornant la partie tlmlit lot au nor«l-est.Tel qtte le tout Se trouve sans réserve «le la part «le l'emprunteur ».Pour être vendu à la porte «le l'église paroissiale «le ville Mont-St-Hilaire.district de St-Hyacinthe.le TROISIEME jour du mois de MAI, «le l'an 1966.à OXZE heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau «lu Shérif, GÉRARD BsAUDET.St-Hyacinthe, mars 28 1966.14555-13-2-0 TERREBONNE Canada \u2014 Provint» de Québec District de Terrebonne Cour Supérieure ( TVANIEL LE WIN, rabbin, No 56,929.\"j LJ domicilié à Ste-Agathe t des Monts, au numéro 101 de la rue Tour du Lac, district de Terrebonne, demandeur; vs JEAN-MARIE CHARLAND, contracteur, domicilié au numéro 490 de la Montée St-Aubin, au village Lafontaine, district de Terrebonne, défendeur.L'immeuble ci-après mentionné et en la possession du défendeur: « Un emplacement situé au Village Lafontaine, dans le comté de Terrebonne, connu et désigné comme étant le lot numéro trente-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro deux cent six (No 206-37) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Jérôme, avec bâtisses dessus érigée.Cedit emplacement mesurant soixante-dix pieds (70') de largeur en front le long de la rue et soixante pieds (00') de largeur en arrière à la the ninth range and the border between the eighth and ninth ranges, to communicate from this part of lot number three, of the ninth range, to the public road between the seventh anil eighth ranges of the township of Wolfestown.\" To l>e sold \"en bloc\" at the parochial church «loor of St-Fortunat, countv of Wolfe, TUESDAY, the THIRD .lay of MAY, 1966, at TEN o'clock in the morning.Don at Jacques, Sheriff's Office, Sheriff.Court House, Sherbrooke, March 23, 1966.14540-13-2 [First insertion: April 2, 1966] S A I N T \u2014 H Y A C I N T H E Canada - Province of Quebec District «)f St-Hyacinthe C TIE AN HUBERT, retired, No.17.243.ook of reference of the parish of St-IIilaire, registration division of Rouville.umler number four of the official subdivision «if original l«>t number ninety-two (92-4) with a'l buildings t heron erected, to withdraw from saiil lot.a strip »>f land of seventeen feet in width, cnglish measure, tunning from northeast to southwest, taken for the opening and the legation of a street, of fifty feet in width bounding the part of sai«l l«>t.on the northeast.As the whole is without reserve from the part of the borrower.\" To In* sold at the parochial church «loor Mont-St-Hilaire, district t>f St-Hyacinthe, the THIRD «lay of the month of MAY in the year 1000.at ELEVEN O'clock in the forenoon.GÉRARD BeAUDET, Sheriff's Office Sheriff.St-Hyacinthe.M arch 28.1900.14555-13-2-<> TERREBONNE Canada \u2014 Province of Quebec District of Terrebonne Superior Court, ( TVANIEL LE WIN, rabbi, No.56,929.S LJ domiciled at Ste-Agathe ' des Monts, at number 101 Tour du Lac Street, district of Terrebonne, plaintiff; vs JEAN-MARIE CHARLAND, contractor, domiciled at number 490 Montée St-Aubin, Lafontaine Village, district of Terrebonne, defendant.The immoveable hereinafter mentioned and in the possession of the defendant: \"An emplacement situated in Lafontaine Village, in the county of Terrebonne, known and designated as being lot number thirty-seven of the official subdivision of original lot number two hundred and six (No.206-37) on official plan and book of reference for the parish of St.Jérôme, with building thereon erected.The said emplacement measuring seventy feet (70') in width in front along the street and sixty feet (60') in width in arrear to the depth; by QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April $8, Î966, Vol.08, No, to 2388 profondeur; sur cent pieds (100') de profondeur du côté nord-est et quatre-vingt-quinze pieds (95') de profondeur du côté sud-ouest, mesure anglaise et plus ou moins, formant une superficie de six-mille trois cent trente-sept pieds carrés (0,337 p.e.) » Pour être vendu au bureau du Shérif, au Palais de Justice, à Saint-Jérôme, MARDI le TROISIEME jour de MAI, mil neuf cent soixante-six à DEUX heures de l'après-midi.Condition : Comptant.Le Shérif, bureau du Shérif, Villeneuve Huot.St-Jérôme, le 23 mars 1966.14496-13-2-o one hundred feet (100') in depth on the northeast side and ninety-five feet (95') in depth on the southwest side, English measure and more or less forming a superficial area of six thousand three hundred and thirty-seven square feet.(6,337 s.q.) To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House, in Saint-Jérôme, on TUESDAY, the THIRD day of MAY, 1966, at TWO o'clock in the afternoon.Condition: Cash.Villeneuve Huot, Sheriff's Office, Sheriff.St-Jérôme, March 23, 1966.14496-13-2 Canada \u2014 Province de Québec District de Tel rebonne Cour Supérieure, l TVANIEL LEWTX, rabbin.No 56,931.\\ LJ domicilié à Ste-Agathc vdes Monts, au no 101.de la rue Tour du Lac, district de Terrebonne, demandeur.M JEAN-MARIE CHARLAND, eontrac-teur.domicilié au no 490 de la Montée St-Aubin.village Lafontaine.district de Terrel>onne.défendeur.Avie de vente L'immeuble ci-après mentionné et en la pos.»es-\u2022 ion du défendeur: « Un emplacement, de forme et de dimensions irrégulièret, également situé au village Lafontaine.dans le comté de Terrebonne, connu et dé-igné sous le numéro trente-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro deux cent six (no 200-30) des plan et livre de renvoi officiels de ladite paroisse de Saint-Jérôme.('edit emplacement mesurant quarante pieds 110') et quinze pieds (15') de largeur en front le long de la nie cadastrée sous le no 200-29 et cent vingt pieds (120') de largeur en arrière à la profondeur dans sa ligne sud-est; sur cent qua ran te-einq pieds (145') de profondeur dans sa ligne nord et cent pieds (100') de profondeur dans la ligue sud-ouest, mesure anglaise et plus au moins.Avec toutes les.constructions dessus érigée.-*.Pour être vendu au bureau du >hérif au Palais de justice, à Saint-Jérôme.MARDI, le TROISIEME jour de Al AI mil neuf cent soixan-tc-*ix.à TROIS heures de l'après-midi.Condition: Comptant.Le Shénf.bureau du Shérif.Villeneuve Huot.Saint-Jérôme, le 23 mars I960.14497-13-2-o ( 'anadu \u2014 Province of Quelle District of Terrelxmne Superior Court ( TVANIEL LE WIN, rabbi, No.50.931.\\ domiciled at Ste-Agathc * des Monts, at no.101 Tour du Luc stieet.district of Terrebonne, plaintiff, vs JEAN-MARIE CHARLAND.contractor, domiciled at no.490 Montée St-Aubin.village Lafontaine.district of Terrelxmne, defendant.Sot ice of sale The immoveable hereafter mentioned and iu the posses.'ion of the defendant: \"An emplacement, of irregular form and dimensions, also situated in the village of Lafontaine, in the county of Terrebonne, known and designated under number thirty-six of the official subdivision of original lot number two bun-died and six (no.206-30) on the official plan and book of reference of the said paii.-b of Saint-Jérôme.The said emplacement, measuring forty feet (40') and fifteen feet (15') in width in front a'ong registered in cadaster under no.200-29 and one hundred and twenty feet (120') in width in the rear to the depth in the southeast line, by one hundred and forty-five feet (145'.) in depth in the north line and one hundred feet (100'j in depth in the southwest line.English measure and more or less.With all the buildings thereon erected.\" To lx> sold at the Sheriff's office, at the Court House, at Saint-Jérôme, TUESDAY, the THIRD day of MAY.one thousand nine hundred and sixty-six.at THREE o'clock in the afternoon.Condition: Cash.Yii.lenei ve Huot, Sheriff's office.Sheriff.Saint-Jerome.March 23.1066.14497-13-2 ( anada \u2014 Province de Québec District de Terrelxmne Cour Supérieure, / TVANIEL LEWIN, rabbin, No 56,930.\"j *-/ domicilié à Ste-Agathc.'des Alonts, au no 101.de la rue Tour du Lac.Ste-Agathe, district de Terre-honne, demandeur, es JEAN-MARIE CHARLAND.contracteur.domicilié à 490 de la Montée St-Aubin, village Lafontaine.district de Terre-Ixmne, défendeur.Avie de rente L'immeuble ci-après mentionné et en la possession du défendeur: « Un emplacement situé au village Lafontaine.dans le comté de Terrelxmne, connu et désigné connue étant le numéro trente-trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro deux cent ( 'anada \u2014 Province of Quebec District of Terrelxmne Supciior Court, (\"TVANIEL LEWIN.rabbi.No.56,930.< U domiciled at Ste-Agathc Mies Alonts, at 101 Tour du Lac Street, Ste-Agathe, district of Terrebonne, plaintiff, r* JEAN-MARIE CHARLAND, contractor, domiciled at 490 de la Montée St-Aubin.village of Lafontaine.district of Terrebonne, defendant.Sotice of sale The immoveable hereafter mentioned and in the possession of the defendant: \"An emplacement situated in the village of Lafontaine, in the County of Terrebonne, known and de: ignated as being lot number thirty-three of the official ,-ulxlivision of oiiginal lot number 2386 GAZETTE OFFICIELLE ÙE QUÉBEC, 99 avril 1966, 98* mitée, «J six (No 206-33) dea plan et livre de renvoi officiel! de la paroisse «le Saint-l«;iAme.('«\u2022«lit emplacement mesurant soixante-cimj piedl (66*) largeur; sur cent un punis et sept centième! de pied (lOl.07') «!«\u2022 profondeur «lans el cinquante centièmes «!«\u2022 pied (100.600 «le profondeur «lans sa ligne sud-est, nu-sure anglaise el plus ou moins.Avec toutes les con-1 ruction- dessus érigée.-.\" Pour être vendu au bureau du Shérif au Palais de Justice n Saint Jérôme, MARDI, le TROISIEME jour de MAI.mil neuf cent soixuutc-'ix à DEUX heures «t DEMIE de l'après-midi, ( '«militions: comptant.U Shérif.Bureau du Shérif, Villeneuve Hi «>t.Saint-Jérôme, le 28 mari 1066.14639-13-2-o Canada \u2014 Province de Québec District «le Montréal Cour Supérieure, » DR I'D E N TIA L TRU ST No 574 60S.A <<>MPAN V LIMITED.I corps politique et incorporé, ayant sa principale place d'affaires pour la province de Québec en les ville et «listrict «le Montréal, demanderesse, et PAUL L «TOURNE AI', «le St-Pros|>er.district de Beauce, et PERN AND QUIRION, «le St-Pn^r.district de Beauce, défendeurs.An* <\/<\u2022 rente Les immeubles ci-après mentionné! et en la possession «les défendeurs.« Une partie du l«>t 2111 dans le second rang «lu canton «le Granville, mesurant 200 pieds «le largeur par la distance entre la Rivière Ottawa et la propriété «le la compagnie de chemins «le fer Canadien Pacifique de prof«>n«leur et un emplacement adjacent connu et désigné comme partie «lu l«)t 20A «lu«lit second rang «lans ledit canton «le (ïrcnville, mesurant 850 pie«ls par 225 pieds.Ces propriétés étaient autrefois le site «l'hôtel connu comme Montana Inn qui a brûlé il y a quelques années.Pour être vendu à la jMirte «le l'église catholique paroissiale «le Pointe aux Chênes, comté d'Argenteuil, district «le Terrelumne, JEUDI, le VINGT-SIX IÈAIE jour «le AIAI mil neuf cent soixante-six, à DEUX heures «le l'après-midi.(26/5/60 à 2 P.AI.).Comlit ions : ( '«nnpt an t.l.e Shérif, Bureau du Shérif.villeneuve Huot.Saint-Jérôme, le 18 avril 1066.14700-16-2 Canada \u2014 Province «le Québec District «le Montréal (our Supérieure, f WINDLIN REALTIES No09SlS7.\\ *V* INC., corps politique ' et incorporé, dûment constitué connue tel, ayant son siège social et principale place «l'affairés en les ville et district «le Montréal, demanderesse, M ARESVILLE GARDENS INC.et CLOVIS ARES, défendeurs, et ARES INC., corps politique et incorporé, dûment «\u2022«institué comme tel.ayant son siège social et principale place d'affaires en les ville et district «le Montréal, mis-en-cause.1 ri.s de rente Les immeubles ci-après mentionnés en possession «lu mis-en-cause.two hundred and six (Xo.200-33) of tin- official plan and book of reference «>f the parish nf Saint.Jérôme.This sai«l emplacement measures sixty-live feet (66') in width; by one hundred and one feel and seven hundredths of a foot (101.07') in depth in its north-west line and one humlred feel ami hundredths of a foot (100.50') in depth iu iu south-east line.English measure ami moo or less.With all the constructions erected thereon.\" To be s«>'«l at the Sheriff*! Office, m the Court House «>f Saint-Jérôme.TUESDAY, the THIRD day of MAY.one thousand nine humlred and sixty-six at TWO-THIRTY in the afternoon.( 'onditions: cash.Villeneuve Hi ot, Sheriff*! Office, Sheriff.Sainl-Jérôme.March 23.1000.14639-13.2 ( 'anada \u2014 Province of Queljec District of Alontreal Siq>crior Court, t PRUDENTIAL TRUST No.674 668.< * COMPANY LIMITED, a IkxIv oor|x>rate, having its principal place of business for the Province nf Quelx'c in the citv ami «listrict «>f Alontreal, plaintiff, vs PAUL LETOURNEAU, of St.Pros|M-r.district of Beauce, ami EERXAND QUIRION, of St.Prosper, «listrict of Beauce, défendants.Notice of .sale The undermentioned immoveables and in the possession of the defendants.\"A part of lot 24B on the second range of the township of (Jrcnville, measuring 200 feet in width by the «listance between the Ottawa River ami the property of The Canadian Pacific Railway Company in depth and an adjoining emplacement known and designated as part of lot 20A of the said second range in the said township of Granville, measuring 860 feel by 225 feet.These properties were formerly the site of the hotel known as Montana Inn which burned down some years ago.\" To lie sold at the parochial Catholic church «loor of Pointe aux Chênes, county of Argenteuil.district of Terrel>onne, THURSDAY, the TWENTY-SIXTH «lay of MAY one thousand nine humlred ami sixty-six.at TWO o'clock in the afternoon.(28/5/66 at 2 P.AL).Conditions: Cash.Villeneuve Huot, Sheriffs Oflice, Sheriff- Saint-Jérôme, April IS.1000.14700*16-2-0 ( 'anada Province of Quebec District of Montreal Superior Court, i TuTINDLIN REALTIES No.09S 1S7.-j 1V1 INC., a body politic ' and corporate, duly incorporated as such, having its head office and principal place «>f business in the citv ami district of Montreal, plaintiff, as ARESVILLE GARDENS INC.ami CLOVIS ARES, defendants and ARES INC.a body poli lie and corporate, duly incorporated as such, having its head oflice and principal place of business in the city and «listrict «>f Montreal, nus-en-ceuse.Notice of .sale The undermentioned immoveables in the possession of the mis-en-cnusc. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, Km, Vol.os, Xo.m 2387 d) Subdivision quarante-trois du lot originaire cinq ©cut trente-sept (537-13) aux plan et livre (le renvoi officiels «h- la paroisse «le Si-Louis «le Terrebonne; h) Subdivision quarante-quatre du loi originaire cinq cent trente-sept (537-44) aux plan et livre de renvoi officiels «le la paroisse «le St.Louis «le Terrebonne.INnir être vendu à la porte «le l'église paroissiale catholique «le Terrebonne, comté our satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires et autres impositions, ainsi que les frais encourus pour et par la vente, à moins que ces taxes et autres impositions et dépens ne soient payés avant la vente, à savoir: ll«:e sold by public auction at the office of the Council, at the Town Hall in the said town of Richmond, the NINETEENTH day of the month of AI AY, 1000, at TEX o'clock in the forenoon, (advanced time) to satisfy the payment of the municipal and school taxes and other impositions ami costs incured by the sale, unless these taxes and other impositions and Costs be paiok of references for the town of Richmond.Taxes: $390.82.Estate Jean Roberge.\u2014 Lot number five hundred and tow subdivision A (502A) on the cadastral plan and lx>ok of references for the town of Richmond.Taxes: $4.49.Estate Jean Roberge.\u2014 Lot number five hundred and two subdivision B (502B) on the cadastral plan and Ixwk of references for the town of Richmond.Taxes: $157.45.Estate Jean Roberge.\u2014 Lot number five hundred and two subdivision C (502C) on the cadastral plan ami l>ook of references for the town of Richmond.Taxes: $24.78.Lamarche, Roland.\u2014 Lot number three hundred and sixty-nine (309) on the cadastral plan and l)ook of references for the town of Richmond.Taxes: $252.71.Given at Richmond, Quebec, this 18th «lay of April, 1900.Gilles Duchabme, 14814-10-2-o Secretary- Treasurer.INDEX No lift VRRÊTÉS en Conseil ORDERS in Council 151 - Régie des rentes «lu Québec.2322 151 - Quebec Pension Board.2322 507 Classement d'objets mobiliers et artistiques appartenant à la Fabrique «le la paroisse de St-François, Ile d'Orléans., \u2022.¦ 2335 507 - Classification of moveable and artistic objects belonging to the Fabrique «le la paroisse «le St-François, Island of Orleans.2325 571 - Casques protecteurs.2320 571 Safety helmets .2320 2888 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 23 avril 190(1, US' année.n° 10 ASSEMBLÉE MEETING Aima ftJonquièrei Railway Company (The).8326 Compagnie du chemin de fer Aima & .fompiières (La).2326 \\SSOCIATIONS Coopératives ASSOCIATIONS Cooperative Association coo|H''rative de l'école secondaire Le Ber (Form.).2326 Association coopérative de travail de Rivière Davy (Nom Xame eh.).2327 Association coopérative d'hahitation de Maniwaki (Form.).2327 Association coopérative du collège Mont-St-Louis (Form.).2327 Association coopérative du corps étudiant du collège St-Paul (Form.).2327 Association coopérative forestière de l'Ascension de Patapédia (L*) (Form.).2327 Association coopérative téléhision de Percé (Nom Xame eh.).232s1 AVIS NOTICES Aboussafy, Marie-Yvonne (Requête Edition) .2328 Dubé (J.B.) Ltée (Barrage).2320 Dubé (J.B.) Ltd.(Dam).232!» Ileldmarier, Claudia Romana (Requête - Petition).2328 Jakim.Kaz Leopold (Nom Xame eh.).232s Klenk.Perry (Requête - Petition).2329 Loi électorale de Québec (Agence de publicité).2330 Loi électorale de Québec (Agents officiels).2330 Quebec Election Act (Official agents).2330 Quebec Election Act (Publicity agency).2330 Rottenberg.Svdnev (Requête - Petition).2336 Sediey.Léo (Xom - Name ch.).2329 Yalmont.René (Nom - Name ch.).2329 Winrow.Robert Michael (Norn - Name ch.).2320 Zemelman, Thomas (Requête Petition).2320 CAISSES SAVING d'épargne et de crédit and credit unions Caisse d'Economie des travailleurs de Drummondville (Form.).2331 ( 'aisse Populaire de Schefferville (Form.) 2331 COMPAGNIES COMPANIES Avis relatifs Notices relative à la loi des to the Act of Autorisées Licensed à faire des affaires to do Business Hamac-Hansclla Machinery Corporation.2332 International Savings and Mortgage ( 'orporation.2331 Taxes Instruments Incorporated.2332 Chartes \u2014 Charters \u2014 Abandon de Surrender of Arba Corp.2333 Brookficld Corporation.2334 Chambly Lands Limited.2333 Compagnie Regal Limitée (La).2334 Curling St Hyacinthe Incorporée (Ix*).2333 Dolphin Swimwear lue.2332 Huron-British Footwear Ltd.2334 Immeubles Cimon Inc.(Les).2333 \u2022lane Apartments Ltd.2332 Mountview Plaza lue.2333 Nomic I ne.2331 Normandie Gardens Corp.2336 Pâtisserie Cousin Inc.2334 Radel Realty Inc.2335 Regal Company Limited.2334 Terrebonne Investments Inc.2333 Dissoutes Dissolved Argenteuil Cable Vision Inc.2335 Bayridge Estates Ltd.2335 Bourget Construction Inc.2335 S.Cadieux & His lice.2335 Canadian Dinette Co.2335 Canscot Building Limited.2336 Carleton Holdings lue.2330 Cie d'Auteuil ltée (La).2336 Code Realties Ltd.2330 Continental Sewing Machine Co.Ltd.2336 D'Auteuil Co.Ltd.2330 Desjardins (Eugène).Ltd.2336 Elda Jewellery Manufacturing Company Limited.333* Intersigs ltée.2337 Klaar (YY.) (Canada» Ltd.2337 Lawrence Fabrics Ltd.2337 Leblanc (Jos) limitée.2337 Iyondon Garage Ltd.2337 Macon Investments Limited.233] Maçonnerie moderne ltée.2338 Maple Investment Corporation 233s Marlborough Golf & Country Club.Limited.2338 Mai loll Investments Limited.2338 McBee Company.Limited (The) 2338 Modern Masonry Ltd.2338 Modern Stucco & Terruzzo Co.Ltd.2338 Mountain City Motors Ltd.2338 New York Investment Corporation.2339 Park Holdings Ltd.\u2022 2330 Pointe Claire Barbecue & Spaghetti House Inc.233!» Quebec Cinema Scope T.Y.Ltd.2339 Divers Miscellaneous Béliveau Paltcrnworks Inc.(Dir.).2339 Bel Alumium Industries Ltd.(Dir.).2349 Club de chasse ù tir de Québec (Le) (Règl- liy-laus).2310 Compagnie de Fiducie Prêt et Revenu (Dir.).2341 Coopéraiio inc.(Dir.).2340 Creative Photographers Ltd.(Dir.) 2340 De-Mix ltée (Dir.).2310 Kehal Israel Association Inc.(Rcgl.Rq-laws).2340 Lempirs Alines.Ltd.(Dir.).2311 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 23, 1906, Vol.98, No.Hi 2889 Divers Miscellaneous (suite) (continued) Loisirs paroissiaux do Sault-au-Mouton (Les) (Régi- By-laws).2340 Parkdalc (1986) Inc.(Dir.).2341 Producteurs de lait nature de Montreal inc.(Le«) (RègL- By-laws).2340 Quebec Society of Plastic ami Reconstructive Surgery (The) (By-laws).2341 Reygo Vacuum inc.(Dir.).2341 St.Joseph's House of Ilospitalitv Inc.(RègL- By-lairs).2339 Savings and Investment Trust CompanA' (Dir.).2341 Société de Chirurgie Plastique et Reconstructive du Québec (La) (Régi.) 2341 Lettres patente» Letters Patent A.L.équipement inc.2280 A.L.Equipment Inc.228(i Agence de voyage Intercontinental inc.2280 Amiga inc.2287 Arsenaiilt Aircraft Services Inc.2287 Association des commerçants et hôteliers de Ste-Anne-de-Beaupré.2287 Association des employés indépendants de Ciment Indépendant inc.(L') .22SX Associés des Iles inc.(Les).2298 Auto-Lave du boulevard inc.2288 Autos-Repos, inc.228K Ix- Bergerac inc.2289 Bouchard (Gilles) ltée.2289 Bouchard (Ludger) inc.2289 Boucherie Papineau ltée.2290 Boulevard Car-Wash Inc.2288 Boutique du soulier inc.2290 Brujohn Properties Ltd.2290 Centre Dumar inc.2291 Centres d'achats du Nord (Canada) limitée (Les).2304 Charron (Jacques) construction ltée.2291 ( 'lub de chasse à tir de Québec (Le) 2291 ( lub Optimiste Saint-Jean inc.2292 ( 'omité de loisirs de Charke City.2292 ( 'omité des loisirs St-Cyrille-de-Wendover inc.2292 Compagnie Cemalian ltée.2293 ( onseil du Patronat du Québec inc .2293 ( ontinental Store (Du Lac) Ltd.2301 ( 'orporation d'investissement Italcan.2298 Dixon Van Lines (Montreal) Limited.2293 Domaine Mont-Joly du Lac Pauzé inc 2294 Dream Lounge Inc.2294 Dubeau & Giroux Inc.2294 Dumoulin (Robert J.) Investment Corp.2295 Dyotte (Albert) & fils inc.2295 Eagle (Wilf) Limited.2295 Entreprises Del-Champ inc.(Les).229(5 Entreprises Halo ltée (Les).2290 Faucher (Emile) inc.2290 G.Ai.T.Stencil Cutting Machine Co.Ltd.2290 Great Whale River Community Association .2297 Immeubles G.B.G.inc.(Les).2297 Intercontinental Travel Bureau Inc.2280 Institut de Réhabilitation Richelieu I>our les enfants handicapés, inc.2297 Island Associates Inc.2298 Italcan Investment Corporation.229S Jurado Investments Ltd.2299 L & W Investments Inc.2299 Laroche draperies (Sorel) inc.2299 Local Metal & Waste Ltd.2300 Loisirs de Tchitagama inc.(Les).2300 M.& M.Hobby limitée.2300 Magasin Continental (Du Lac) ltée.2301 Magasin (Juy inc.2301 Marché Lachance inc.2301 Mercure (Louis) automobiles inc.2302 Mercury Adjustment Bureau Inc.2302 Monten Corporation.2302 Mont-Joly's Estate of Lake Pauze Inc 2294 Montreal Royal Regiment of Canadian Artillery \"Numbers One\" Club.2303 Murray Hill Equity Ventures Inc 2303 New Dream Lounge Bar Inc.2303 Normand (E.) inc.2304 Northland Shopping Centres (Canada) Limited.2304 O.T.J.Ste-Rosalie.2304 Oxford and Mansell Incorporated.2305 P.B.Properties Ltd.2305 P & H Specialties Co.Ltd.2305 Papineau Butchers Ltd.2290 Patsilk Investment Club Inc.2305 Patterson (B.) Garage Inc.2300 Placements Elcano inc.(Les).2300 Placements Grande Allée inc.(Les) 2300 Polygraph Printing Inc.2307 Provisions de choix inc.(Les).2307 Quebec Association of Teachers of Education.2307 Raphael 67 inc.2308 Rentner (Maurice).2308 Restaurant Thomas inc.2308 Restaurants « La Caravelle » inc.2309 S.AI.R.Equipment Inc.2309 Les Sacs à main Grand Prix inc.2309 Salon McGill Beauty Shoppe inc 2310 Senro Investment Corp.2310 Shedlack Ltd.2308 Shoe Boutique Inc.2290 Simard Amin inc.2310 Société Gesbec inc.2311 Société Sèze inc.2311 Studio de Santé de Ste-Foy ltée.2311 Syndex inc.2312 Taverne Concorde inc.2312 Theatre Technology of Quebec.Ltd 2312 Thomas & Dilworth Ltd.2313 Thomas Restaurant Inc.2308 Vitrerie Harvey ltée.2313 Voix des parents de la régionale Louis-Hémon (La).2313 Vulcan Inspection & Drafting Ltd.2314 Williams (Ronald) Inc.2314 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Alba Corporation.2314 Almar Imports Inc.2315 Association provinciale des infirmiers du Québec.2315 Benoit & Kersen Ltd.2315 Bétons Drummond ltée.2317 Bibliothèque des Sources ( La ).2315 Boyer (Yvon) inc.2315 Brulotte (Marcel) ltée.2310 Calendrier & bottin téléphonique du centre social italien de l'Est inc 2310 Casualaire inc.2310 Centre audif du Québec inc.2310 Corporation des loisirs St-André inc.(La).2310 Dopat Flooring Inc.2316 Dozois - St-Jean limitée.2317 Drummond Ready Mix Ltd.2317 East veld Industrial Realties Corp 2317 2300 GAZETTE OFFICIELLE DE QU fill El ', 2d avril 19m, 98' année, n° Hi lettres patentes Supplementary suplémcntaircs Letters Patent (suite) (continued) Equipements Universels Napierville inc.2317 Gittleson Holding! Incorporated.2317 Hogan, McCuaig and Hood Ltd.2318 Irwin Dress Co.Ltd.231S Joshar Incorpora ted.23 IS Laiterie Shefford limitée (La) .231K Landreville automobiles inc.2319 Maton (Bert) & Son Inc.2319 New Casa de la Pizza lue .2319 Pascal Realties Limited .2319 Penny-Lou Corporation.2319 Placements La Vigueur inc.2319 Quebec Hearing Aid Centre Inc.2320 Raymond-Stephen Mortgage & Investment Corp.2320 Rocheleau automobile ltée.2320 Ste.Rose Land Sales Inc.2320 Scenic Realty Corp.2321 Shefford Dairy Limited .2318 Simkovits Holdings Ltd.2321 Sources Library.231\") Starto-Jet inc.2322 Super-Marché Raymond ltée.2322 Télécommunications de l'Est limitée.2323 Siège» sociaux Head Offices Basinet Eue.2341 Bienville Inc.2334 Entreprises K.Renaud inc.(Les) 2342 Heaters.Limited.2342 Lemoyne & tirant lue.2343 Marché Lachance Inc.2343 Maron < 'oust met ion ( 'orporation.2342 Paton Manufacturing Company, Limited.2342 Productions Robard Inc.(Les).2343 Renaud (K.) Entreprises Inc.2342 Revgo Vacuum inc.2343 Star Brusll ltée Ltd.2343 Théâtre lyrique de Montréal inc.(Le) 2342 Waterman Canada Inc.2342 DEMANDES APPLICA TIONS à la Législature to Legislature Hull, cité - city .234Ô Longueuil, cité - city .2344 Pincourt.ville - town.2344 St.Andrews Coif Club Inc.2344 Liquidation, avis de Winding up \\otice Caisse Populaire Dcsjardins de Sainte-Paule (La).2346 MINISTÈRES DEPARTMENT! L Affaires municipale» Municipal Affairs Rélair, ville - town (Règl, By-law B-H) 2345 Marieville, ville - town (Annex.).2347 Sully, mimic.(Nom - Name ch.).2330 Agriculture Agriculture et colonisation and Colonization Southwestern Protestant Settlement Society (The).234S Education Education Municipalité .scolaire de: School Municipality of: Beauceville (Dem.- Appt.).234S Bcauccvillc-Est-East.ville-town (Dem.- Appl.).234S (Sap St-Martin (Dem.- Appl.).2340 Chomedey Catn.(Dem - Appt.).2361 Clermont (Ace- Grant.).2340 Earnham-Ouest - West (Dem-Appl.) 2;'.\">l Jacques-Cartier, c.s.c.(Ace- Grant.).2340 Lalonde, c.s.r.- r.s.b.(Ace- Grant.).2340 La Sarre, par.(Dem - Appl.).2340 IiOtbinièrc par.(Dem - Appl.).2351 Montréal, c.s.c.(Ace- Grant.).2350 Rosemère Cath.(Ace- Grant.).2350 St-Athanase (Dem.- Appl.).2340 St-Cyriac (Dem - Appl.).2351 St-Félicien.ville town (Don.- Appl.) 2348 St-Félicien.par.(Dem - Appl.).23 Is St-François-du-Lac (Ace- Grant.) 2350 Ste-Monique (Ace- Grant.).2350 Finances Finatuc Assurances: I neurones: Home Fire and Marine Insurance Company of California.2361 Industrie Industry et Commerce and Commerce Avis de pêche aux coques.2352 Shell fishing notice.2352 Travail ËMsour Industrie ou métiers de: Industry or Trades of: Building materials, Province (Amend.) 2354 Construction, Drummondville (Prêl- Levy).2364 Fourrure, gros, Montréal (Prêt.).2356 Fur, wholesale, Montreal (Levy).2356 Matériaux de construction, province (Mod.).2354 Métal en feuilles, Montréal (Mod.) .2353 Sheet metal, Montreal (Amend.).2353 NOMINATIONS APPOINTMENTS Présidents d'élection.2358 Returning-Officcrs.2358 PROCLAMATIONS PROCLAMA 770 \\S Brefs d'élection.2359 ( onvocation de la Législature.2358 Convocation of the Legislature.2358 Dissolution de la Législature.2360 Dissolution of the Legislature.2360 Election Writs.2350 SOUMISSIONS TENDERS Lac Mégantic, ville.2362 Lake Mégantic, town.2362 Notre-Dame-de-Laterrière, par.2360 Québec-Ouest - West, ville - town.2361 St-Jérôme, cité - city.23(11 St-Pierre, ville - town.2365 Touraine, munie.2366 Val Morin, munie.2367 Villeneuve, ville-town.2368 SYNDICAT SYXDICAIE Professionnel Professional Association des policiers provinciaux du Québec (Const.- Inc.).2360 VENTES SALES Effets non-réclamés Unclaimed Goods Canadian Pacific Express Company.2370 QVEHEC OFFICIAL GAZETTE April 23, 1906, Vol, 98, So, 16 2301 Montreal Montreal Riendcau vs Courteau.2378 Nicolet Mcolet Office du Crédit Agricole du Québec (L') vs Deniers.2878 Quebec Farm Credit Bureau (The) ai Deniers.2370 Québec Quebec Kolostat Heating Systems Limited vu C.Johin Limitée et al.3380 Noreau (Albéric) Inc.vs Verreault .237!) Roberval Roberval Metropolitan Live Insurance Company vs Castonguay.2882 Saguenay Saguenay Tremblay vs Boily.2882 Saint-François .Saint Francis Office du Crédit Agricole du Quél>ec (L') vs Tunnel.2383 Quebec Farm Credit Bureau (The) vu Tunnel.2383 Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe Hubert p.v Duranleau .2884 Terrebonne Terrebonne Lewin vs Charland.2384 Lew in vs Charland.2385 Lewin vs Charland.23S5 Mindlin Realties Inc.vs Aresvillc Gardens Inc.et al.2386 Prudential Trust Company Limited vs Létourneau et al.2386 Taxes Taxes Richmond, ville-town.2387 Licitation Licitation Immeubles Rouville Inc.(Les) vs Morin et vir.2370 SHÉRIFS SHERIFFS Beauce Beauce ( i rondin vs Rodrigue.2372 G rondin vs (i rondin.2373 Office du Crédit Agricole du Quel ht (L') vs Paquet.2372 Quebec Farm Credit Bureau (The) vs Paquet.2372 Bedford Bedford Doucet vs Fleury.2873 Chicoutimi Chicoutimi Algonquin Capital Corporation Limited vs Boulianne.2374 Banque Royale du Canada (La) vs Ca- ron.2374 Royal Bank of Canada (The) vs Caron.2374 Hull Hull Pettapiece Bf Laa Entreprises Dicair Limited.2375 kamouraska Kamouraska Office du Crédit Agricole du Québec (L') vs Belzile.2376 Quebec Farm Credit Bureau (The) vs Belzile.2370 \\ I égan tic Mégan tic Veillera vs Gauvin.2377 Montmagny Montmagny Caisse Populaire Dcsjardins Paroissiale de St-AIagloire (La) vs Laverdière.2378 Le Ministère des Postes, à Ottnwn, a autorisé l'affranchissement M numéraire et l'envoi comme otijet de deuxième dusse de la présente publication.Authorised as second class mail by the Post Office Department, Ottawa, and for payment of postage in cash. "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.