Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 11 juin 1966, samedi 11 (no 23)
[" 98e année vol.08 N° 23 3165 te JUIN 1966 kxetle officielle fie //uekc QUEBEC OFFICIAL GAZETTE Ouébce, samedi 11 juin 1966 Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la reine, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en es! faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.1° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plu-.ô° L'abonnement, la vente de documents, etc.sont strictement payables d'avance.b° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du Ministre des Finances.7° La Gazette officielle de Québec est publié le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi^ à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur da la reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Imprimeur de la reine avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Qiielxv, Saturday, June 11, 1966 Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Parliament Buildings, Quebec.2.Supply advertising copy in the two official languages.When copy is supplied in one language only, the translation will l>e made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Pay cash and l>eforc publication for advertising copy according to the rates set forth below, exception when the copy is to be published several times.It that event, the interested party shall pay upon receipt of his account and before the second insertion: otherwise this insertion will l)e suspended without further notice and without prejudice to the Queen's Printer who will refund any overpayment.5.Subscriptions, price of documents, etc., are payable strictly in advance.6.Remittance must be made to the order of the Department of Finance, by cheque or money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the dead line for receiving notices, documents or advertising copy expires at noon on Wednesday, unless it is a holiday.In tliat event the dead line is noon, on Tuesday.Notices, documents or advertising copy not received on time will be published in a subsequent edition.Moreover, the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, l>ecause of their length or for reasons of administration.8.Any demand for cancellation or any remittance of money is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer l>efore the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Publiée par le Gouvernement de la Province / Published by the Provincial Government L'Imprimeur de la reine, ROCH LEFEBVRE, Quecn'a Printer \u2014 Québec 3160 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 11 juin 1900, 98' année, n° 23 Tarif de» annonces, abonnements, ete.Première insertion: 30 cents lu ligne agate, pour chaque version, (M lignes un pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertion! subséquentes: 10 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $1 des 100 mots.Exemplaire séparé: 40 cents chacun.Feuilles volantes: $1.80 la douzaine.Abonnement: $10 par année.N.Bt\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture: le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui OU nombre d'insertion, et la lettre « 0 » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre tradustion.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.VImprimeur de la reine, Rocu Lefebvbe Hôtel du Gouvernements Québec, S mai IMS 13377 \u2014 l-52-o AdvertiHÎng, Kates, Subscript ion», etc.First insertion: 30 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: SI per 100 words.Single copies: 40 cents each.Slips: S 1.50 per dozen.Subscriptions: $10 per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of QOticei have the following meaning: The first figure refers to our document muni i r; the second to that of the edition of the Gazillf for the first insertion; the third to the number of insertion, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our trans, hit ion.Notices published but once are follow-d only by our document number.Rocn Lbfebvbe, Queen's I'rinter Parliament Building*! Quebec.May 6, 1962 13377 \u2014 l-52-o Lettres patentes A-l Die Casting Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour d'avril 1966, constituant en corporation: Leonard Livennan, avocat.671.Bertrand.St-Laurent.Israel H.Kaufman, avocat, 10960.Jamcs-Morrice.Marina (\"haros, 3875, Plamondon, app.11, et Annie McNamee, 1445, Aylmer, app.15, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, ces trois derniers «le Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de moules en aluminium et en zinc, alliages de métaux et de leurs composés, sous le nom de « A-l Die Casting Ltd.».avec un capital total de $40.000, divisé en 2.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 2.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le.Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Doivillk.15440 1804-60 Abeam & Palmer inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accortlé des lettres patentes, en «late «lu 29e jour d'avril 1966, constituant en corporation: Anthony Ahcam, York (Sandy Beach).William Palmer.York (Sunny Bank), tous deux industriels, et Jean-Paul Duguay, comptable agréé, Gaspé, pour les objets suivants: Faire affaires comme producteurs et distributeurs «le liqueurs douces et de bière, sous le nom «le « Ahcam & Palmer inc.», avec un capital total «le $50,000, divisé en 5,000 actions ordinaires «le $10 chacune.Letters Patent A-l Die Casting Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late tl\" 28th day of April.1900.have been issued b\\ the Lieutenant-Governor of the Province, inoor porating: Leonard Liverman.advocate.671 Bertrand.St-Laurent.Israel II.Kaufman, advo cate, 10900 Jamcs-Morrice, Marina Charos, 3875 Plamondon, Apt.11.and Annie McNainec.1445 Aylmer.Apt.15, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, the latter three of Montreal, for the following purposes: To deal in aluminum and zinc castings, metal alloys and their compounds, under the name of \"A-l Die Casting Ltd.\".with a total capital Stock of $40.000, divided into 2.000 common shares of a par value of $10 each ami 2,000 preferred shares of a par value of $10 each.The hea«l of lice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dot ville.Assistant Secretary of the Province.15440-o 1804-00 A h cam & Palmer inc.Notice Is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 29th day of April, 1966.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Anthony Ahearn.York (Satuly Beach), William Palmer.York (Sunny Bank), both industrialists, and Jean-Paul Duguay, chartered accountant, Gaspé, for the following purposes: T«> carry on business as producers ami distributors of ¦oftdrinks ami lx'cr, under the name of \"Ahearn & Palmer inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 5.000 common shares of $10 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Aune 11, 190(1, Vol.98, No.3167 Le liège stM'inl de lu ctimparnic est à York Havre de Gaspé), district judiciaire de Gaspé.Le Sous-secrétaire de la province, raymond DoL'VILLK.15440-0 1802-66 The head ofliee of the company is at York (HAvre de (Jaspé), judicial district of Gaspé.Raymond Do u villk, Assistant Secretary of the Province.15440 1 502-60 Aubin & St-Onge inc.Axis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en d»te «lu 21e jour d'avril 1900.constituant en corporation: Serge St-Onge, marchand, Claire Daou&t, ménagère, épouse con-tractuellement séparée de biens dudit Serge St-Onge, tous deux «le 761, 39, avenue, et Gaston Aubin, marchand, 9515, boulevurd Lasallc, tous trois «le LaSalle, pour les objets suivants: Paire Affaires comme marchands de tabac, sous le nom f no nominal value and 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 9515 Lasalle Blvd., LaSalle.judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.15440 160S-66 Belair Wholesale Distributors Inc.I hi air \\\\ ho legale Distributors Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Ijo'i «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a secondé des lettres patentes, en «late du 26e jour «l'avril 1966.constituant en corporation: Irving I.Finkelberg, 652, avenue Outremont.Outretnont.John L.Liber-nian.7487, chemin Spring, (V)te-St-Luc, et Gerald G*.Freed, 1390, Carol Crescent.Laval, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce de chocolat, cacao, sucre, empois, essences, noix, huiles, produits laitiers, bonbons et provisions «le confiserie «le toutes s«>rtcs et procédés, sous le nom de « Belair Wholesale Distributors Inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 10.000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $1 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie est 3032 ouest, rue Notre-Dame, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Dou villk.15440 1733-66 Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing «late the 26th day of April.1006, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Irving I.Finkelberg, 652 Outremont Avenue.Outremont.John L.Lil>erinan.7487 Spring Road.Côte-St-Luc, and Gerald G* Freed, 1396 Carol Crescent.Laval, all three advocates, for the following purposes: To deal in chocolate, cocoa, sugar, starches, flavourings, nuts, oils, dairy produce, candy and confectionery supplies in all forms and processes, under the name «>f \"Belair Wholesale Distributors Inc.\", with a total capital stock of S40.C00, divided into 10.000 common shares of a par value of $1 each ami 3.000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at 8632 Notre-Dame Street West.Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymond Doi:villk, Assistant Secretary of the Province.15440-o 1733-66 Bridge Dry Cleaning Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour d'avril 1966, constituant en corporation: Irving Halperin, 5609, chemin Queen Mary, Hampstead, Daniel Morris, 0165, Notre-Dame-de-Grûce, Montréal, tous deux avocats, et Georgette Lavoie, secrétaire, fille majeure, 217, rue Georges-Yanier, Laval, pour les objets suivants: Exercer le commerce de nettoyeurs, presseurs, teinturiers, buandiers et répareurs de vêtements, tissus, marchandises et ameublement de maisons, sous le nom de « Bridge Dry Cleaning Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Bridge Dry Cleaning Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 27th day of April, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Irving Halperin, 5609 Queen Mary Road, Hampstead, Daniel Morris, 6165 Notre-Dame-de-Grâce, Montreal, both advocates, ami Georgette Lavoie, secretary, fille majeure, 217 Georges-Vanier Street, Laval, for the following purposes: To carry on the business of cleaners, pressors, dyers, laundcrers and repairers of clothing, fabrics, goods and household furnishings, under the name of \"Bridge Dry Cleaning Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each aud 3,000 preferred shares of $10 each. 3168 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Il juin 1900, 98' année, n° 23 Le siège social «le la compagnie est 5401, avenue Verdun, Verdun, district jiuliciairc île Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.15440 1781-06 Byway Holding Corp.Ltd.Avis est donné Qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé des lettres patentes, en «late du 27c jour «l'avril 1006, constituant en corporation: .lack Lightstone, 3555, Côte-des-Neiges, Montreal, Jacob L.Rot h-man, 7020, chemin Kingsley, et Marvin Riback, 5621, avenue Palmer, ces deux «lerniers «le Côte-St-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de « Byway Holding Corp.Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2.000 actions ordinaires de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées «le 810 chacune.Le siège social «le la compagnie est 3405, rue Mountain, Montréal, district jiuliciairc «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.15440 1780-00 C.M.R.«électrique limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé «les lettres patentes, en date «lu 20c jour «l'avril 1966, constituant en corporation: Pierre Lalondc.avocat, 10420, Grande-Allée, Lise Bédard, secrétaire, épouse séparée «le biens «le Guy Béranl, 10012, rue Ducharme.tous deux «le Montréal, et Françoise Dumais, secretaire, fille majeure et usant «le ses f the Province, incorporating: Jean-Marie Caya, industrialist, Jeannine Nadeau, housewife, wife séparât*' as to property «)f the said Jean-Marie Caya.and Omer Nadeau, annuitant, all three of Yictoriaville, for the following purposes: The industry ami business dealing in lumber, under the name of \"J.M.Caya ltée\", with a total capital stock «>f 875,000, divided into 250 common shares of a nominal value of 8100 each ami 500 preferred shares of a nominal value of 8100 each.The head office of the company is at Yictoriaville, judicial district of Arthabaska.Raymond Douvillk, Assistant Secretari/ of the Province.15440 1807-66 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Aune 11, 1Û68, Vol.98, No.23 3109 Centennial Motors Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant iroiiverneur de la province a accordé des lettres patente!, en date du 29e jour d'avril I960, constituant SO corporation: Rolland Pickford, vendeur, 29, Paquiu, St-Raphaiil-dc-l'Ile-Bizard, Albert A.Adam, vendeur, 3042, Broadway, l.aehinc, et James Cameron, vendeur, 8831, Old Orchard, Montréal, pour les objets suivants: l'aire le commerce de véhicules automobiles .1 faire affaires comme garagistes, sous le nom de « Centennial Motors Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 100, 0e Avenue, Lachine, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.i.V140-o 1754-06 Centennial Motors Inc.Notice is given that under Part I of the Coinpanie- Act, letters patent, bearing date the 20th day of April, 1960, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Rolland Piekford, salesman, 29 Pauuin, St-Raphaël-de-1'Ile-Bizard, Albert A.Adam, salesman, 3042 Broadway, Lachine, and James Cameron, salesman, 3831 Old Orchard, Montreal, for the following purposes: To carry on business dealing in automobiles, and to act as garagemen, under the name of \"Centennial Motors Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company is at 190, 6th Lachine, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440 1754-66 Centre d 'alum in in m de Montréal ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé des lettres patentes, en date du 28c jour d'avril 1966, constituant en corporation: Allan B.Frank, Joyce Frank, épouse dudit Allan B.Frank, tous ileux avocats, 3655, Ridgewood, app.407, et Louise Tremblay, secrétaire, fille majeure, 448S ouest, rue Ste-Catherine, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'aluminium, acier, métal blanc, granit, métaux galvanisés, étain, sous le nom de « Centre d'aluminium de Montréal ltée », avec un < apital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de 81 chacune et 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 4640, boulevard Décarie, suite 105, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440 1S03-G6 Centre d'aluminium de Montréal ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of April, 1906, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Allan B.Frank, Joyce Frank, wife of the said Allan B.Frank, both lawyers, of 3655 Ridgewood, Apt.407, and Louise Tremblay, secretary, spinster of the full age of majority, 4488 St.Catherine Street West, all three of Montreal, for the following purposes: To deal in aluminium, steel, white metal, granit, galvanised metals, tin, under the name of \"Centre d'aluminium de Montréal ltée\", with a total capital stock of 8-10,000, divided into 10,000 common shares of SI each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at 4640 Decarie Boulevard, suite 105, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440-o 1803-66 Chandelles Carol Ann & Johnny's Toy Shop Ltd.Chandelles.Carol Ann & le Magasin de jouets Johnny's ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 2()e jour d'avril 1966, constituant en corporation: Seymour Machlo-vitch, avocat.3495.rue Mountain, app.708.Montréal.Theodore Lee Zeiglcr.émetteur.Carol Ann Zeiglcr.ménagère, épouse séparée de biens dudit Theodore Ia'c Zeiglcr, tous deux de 176, avenue Lockhart, Mont Royal, et Dean Kaye, émetteur.189, avenue Dieppe, Pointe-Claire, pour les objets suivants: Exercer un commerce de jouets, chandelles, nouveautés, meubles, quincaillerie, livres, disques de phonographes, souvenirs, cartes de souhaits, toutes sortes et descriptions d'articles vestimentaires, sous le nom de « Chandelles Carol Ann & Johnny's Toy Shop Ltd.Chandelles Carol Ann & le Magasin de jouets Johnny's ltée », avec un capital total de 810,000, divisé en 15,0(0 actions ordinaires de 81 chacune et 2ô,0.0 actions privilégiées de Si chacune.Chandelles Carol Ann & Johnny's Toy Shop Ltd.Chandelles Carol Ann & le Magasin de jouets Johnny's ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters pateid.bearing date the 20th day of April.1966.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating:-Seymour Machloviteh, advocate, 3495 Mountain Street.Apt.708, Montreal, Theodore Lee Zoigler, broadcaster, Can>l Ann Zeigler.housewife, wife separate as to property of the said Theodore Lee Zeigler, both of 176 Lockhart Avenue, Mount Royal, and Dean Kaye, broadcaster.1S9 Dieppe Avenue.Pointe-Claire, for the following purposes: To deal in toys, candles, novelties, furniture, hardware, books, phonograph records, souvenirs, greeting canls, wearing apparel of every kind and description, under the name of \"Chandelles Carol Ann & Johnny's Toy Shop Ltd.\u2014Chandelles Carol Ann & le Magasin de jouets Johnny's ltée\", with a total capital stock of 810.000.divided into 15,000 common shares of 81 each and 25,000 preferred shares of Si each. 3170 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Il juin 1966, 9S< année, n° 23 I/' siège social de lu compagnie est à Mont- The head office of the company is at Mont real, district judiciaire de Montréal.real, judicial district of Montreal.Le Suns-secretaire de la province, Raymond Douvillk, Raymond Douvillk.Assistant Secretari/ of the Province 15440 1636-06 15440-n 1636-otj r.hurboiincau & frères ltée Charbonneau & frères ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Ix>i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 2Ke jour d'avril 1066, constituant en corporation: Charles Cuzelais, comptable agréé.1160, Croissant de Dieppe, Léonide Lalonde, notaire, 2085, boulevard Lé- vesque, Unis tleux de Laval, et Suzanne Marcotte, secrétaire, épouse de Jacques Soulièrcs, 11532, boulevard Ste-Gertrude, Montréal-Nord, pour les objets suivants: Faire alfaires comme compagnie d'immeuhle.de placement et de construction, sous le nom de « Charbonneau & frères ltée ».avec un capital total de 840,000, divisé en 2.000 actions ordinaires île 810 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 355.Place d'Amiens, Laval, district judiciaire de Montréal* Le Sous-sccrétairc île la prorince, Raymond Douvillk.15440-o 1487-66 Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent.!>cariiig date the 28th day of April.1066, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorpi rating: Charles Cazelais, chartered accountant 1100 Croissant de Dieppe, Leonids Lalonde.notary.2085 Lévesque Boulevard, both oi Laval, ami Suzanne Marcotte, secretary, wife of Jacques Soulièrcs, 11532 Ste-(iertrude Houle vard.Montreal North, for the following purpo ses: To curry on business as u real estate, invest ment ami construction company, tinder the Rami of \"Charbonneau & frères ltée\".with a total capital stock of 840.000, divided into 2,000 common shares of 810 each and into 200 pre ferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 355 Plan d'Amiens, Laval, judicial district of Montreal, Raymond Dot villk.Assistant Secretari/ of the Province.15440 1487-60 Les Charpentes d'acier Lesco inc.Lcsco Structural Steel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première parlie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de mai 1966, constituant en corporation: André Levasseur, administrateur, 5392, Jules-Fournier.André Veillette.comptable, 5410.Jules-Fournier.et Jean-Louis Bélanger, agent, 2687, Benjamin-Suite, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce «le l'aluminium, du fer-blanc, du granit, «le métaux galvanisés, «lu fer.«lu cuivre et «le la tôle, sous le nom «le « Les Charpentes «l'acier Lesco inc.\u2014 Lesco Struc-t mal Steel Inc.», avec un capital total de 840.000.divisé en 400 actions ordinaires «le 8100 chacune.Le siège social «le la compagnie est 3033, rue Somerviue, Montréal, district jiuliciairc «le Montréal.Le Sous-sccrétairc de la province.Raymond Douvillk.I5440-o 1572-00 \u2022 Ijes Charpentes d'acier Lcsco inc.lesco Structural Steel Inc.Notice is given that under Part I of tin Companies Act, letters patent, bearing «late the 2n«l day of May.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: André Levasseur, administrator, 5392 Jules-Fournier.André Veillette, accountant, 5410 Jules-Fournier, ami Jean-Louis Bélanger, agent.2687 Benjamin-Suite, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business dealing in aluminium, tin.granite, galvanised metals, iron, copper and sheet metal, under the name of \"Les Charpentes «l'acier Lesco inc.\u2014 Lesco Structural Steel Inc.\".with a total capital stock «>f 840.000.divided into 400 common shares of 8100 each.The head office «>f the company is at 303:'.Somcrville St.Montreal, judicial district of Montreal.Raym«)nd Douvillk.Assistant Secretari/ of the Province.15440 1572-66 Chester Wood Products Ltd.Produits du bois Chester ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, le licutcnant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes, en «late «lu 31e jour de mars 1900.constituant en corporation: Marcel Bouchard, comptable, Arthabaska, Jean Moisan, avocat.2.rue Perreault, Arthabaska.et Gérard Campa-gna.contremaître, Yietoriaville.pour les objets suivants: Industrie et commerce «lu bois, sous le nom de « Chester Wood Products Ltd.\u2014 Produits «lu bois Chester ltée », avec un capital total «le 8125,000, divisé en 750 actions ordinaires de 8100 chacune et en 2,000 actions privilégiées «le 125 chacune.Chester Wood Products Ltd.Produits du bois Chester ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing «late the 31st «lay of March, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Marcel Bouchard, accountant.Arthabaska.Jean Moisan.lawyer, 2 Perreault Street.Arthabaska, ami Gérard Campagne, foreman.Yietoriaville.for the following purposes: The industry ami business dealing of wood, under the name of \"Chester Wood Products Ltd.\u2014 Produits «lu bois Chester ltée\".with a total capital stock of 8125,000, divided into 750 common shares of 8100 each and into 2,000 preferred shares of 825 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Aune II, im, Vol.98, No.88 3171 i.r siège social de lu compagnie est à Chester-le, district jiuliciairc d'Arthabaska.Le Sou.s-secrêtaire de la province, Raymond I)ouvillk.ski-o 1438-06 The head office of the company is at Chcstcr-ville, judicial district of Arthahusku.Raymond Douvillk, Assintunt Secretari/ of the Province.15440 1438-00 le Comité d'organisation de la Conférence internationale de la Famille, inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutcnant-gouverneUT de la province a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour «le février 1866, constituant en corporation sans capital-actions: Alfred Rouleau, directeur général, avenue «les Commandeurs, Levis, Léon-G.Cantin, directeur, 55, rue d'Auteuil, Québec, Marthe Chabot, ians profession, épouse «le Claude Leliberté, 3860, chemin Stc-Foy, Raymond Parent, administrateur, 2860, rue Montreuil, et Hector Char-land, ugent d'administration, 2105, rue Le Bos-i|ti«'t, ces trois derniers de Ste-Foy, pour les objets suivants: Préparer et tenir, à Québec, une conférence internationale «le la Famille de l'Union internationale «les organismes familiaux, dont le siège social et le secrétariat sont à Paris, sous le nom de « Le ('«unité d'organisation «le la Conférence Internationale de la famille, inc.».Ixî montant auquel sont limités les revenus annuels que la cor|>oration peut acquérir et posséder, est «le $100,000.Le siège social de la corporation est à Québec, district judiciaire «le Québec* Le Sous-secrf taire de la province, Raymond Douvillk.i.-.liO-o 700-66 Comité paroissial de St-Émile inc.Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour d'avril 1966, constituant en corporation sans capital-actions: Aurèle Gagné, gérant, 64, boulevard Lapierre, René Lafond, opérateur.70, des Érables ouest, et Florent Boutin, vendeur, 28, l>oulevard Lapierre, tous trois de St-Émile, pour les objets suivants: L'organisation «les loisirs, sous le nom de « Comité par issial de St-Emile inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corix>ration, est de 840,000.Le siège social de la corporation est à Stimule, district judiciaire «le Québec.I^e Sous-secrftaire de la province, Raymon d Douville.15440-o 1791-60 Consolidated Converters Corporation Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le lu Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le lu province a accordé «les lettres patentes, en «late «lu 29e jour d'avril 190(5, constituant en corporation: Sheldon Finkelstein, 5712, avenue Wihlerton, Pinja B.Blitt.4505.avenue Pluiuondon, tous «leux «le Montréal, et Bernard Gardner, 412.chemin Northcote, Rose-mère, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le toutes sortes «le tissus et produits de tissus faits en tout ou en partie «le laine, coton, rayonne, nylon, ou toute autre fibre, naturelle ou synthétique, ou une combinaison d'iceux, sous le nom de « Consolidated l.e Comité d'organisation de la Conférence internationale de la Famille, inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 25th day of February, 1906, have been issue»! by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Alfred Rouleau, general director, «les Commandeurs Ave., Levis, Léon-G.Cantin, director, 55 d'Auteuil, Quel>ec, Marthe Chabot, without profession, wife of Claude Lalilwrté, 3860 Ste-Foy Road, Raymond Parent, administrator, 2800 Montreuil St., and Hector Charland, administration agent, 2105 Lc Bosquet St., the three latter of Ste-Foy, for the following purposes: To prepare ami hold, in Quebec, an international conference on the Family, of Union internationale des organismes familiaux, the head office ami secretariat of which are in Paris, under the name of \"Le Comité d'organisation «le la Conférence internationale de la Famille, inc.\".The amount to which the annual revenue which the corporation mav acquire ami hold is to be limited, is 8100,000.The head office of the corporation is at Quebec, judicial «listrict of Quebec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.15440 799-66 Comité paroissial de St-Émile inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of April, 1966, have l>cen issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Aurèle Gagné, manager, 64 Lapierre Boulevard, René Lafond, operator, 79 des Érables West, and Florent Boutin, salesman, 28 Lapierre Boulevard, all three of St-Émile, for the following purposes: The organization of a recreational centre, under the name of \"Comité paroissial «le St-Émile inc.\".The amount to which is limited the value of the immoveables which the corporation may acquire ami possess, is 840,000.The head office of the corporation is at St-Émile, judicial district of Quebec.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440 1791-66 Consolidated Converters Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing «late the 29th day of April.1966, have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Sheldon Finkelstein, 5712 Wildcrton Avenue.Pinja E.Blitt, 4505 Plamondon Avenue, both of Montreal, ami Bernard Gardner, 412 Northcote Road.Roscmère.all three advocates, for the follow ing pur|x>ses: To deal in all kinds of fabrics and fabric products made in whole or in part of wool, cotton, rayon, nylon, or any other fibre, natural or synthetic or a combination thereof, under the name of \"Consolidated Converters Corpo- 3172 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 11 juin 190(1, 98' année, n° 23 Converters CoriH>rution », uvec un cupitul total tic $40.(100, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 cluu'uuc et 30.000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montreal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.1Ô110 1590-00 ration\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of Si ' and 30,000 preferred shares of $1 each.The head ollice of the eompany is at Mon I real, judicial district of Montreal.Raymond douvillk, Assistant Secretari/ of the Province, 15440-o 1590-60 Continental Maintenance Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, le licutcnunt-gouverneur «le la province a accordé dei lettres patentes, en date «lu 29e jour «l'avril 1900, constituant en corporation: Lucien Lemieux, représentant, 1703, Boisvert, Laval, William Lemelin, organisateur.15, Stc-Anne, Pointe- aux-Tremhles, et Danielle Turcotte, secrétaire, fille majeure, 2020.Nicolet, Montréal, pour les objets suivants: Paires affaires comme nettoyeurs, laveurs et poseurs de stores et fenêtres doubles, sous le nom de * Continental Maintenance Inc.», avec un capital total «le 820.0C0, divisé en 20.000 actions orilinaires de $] chacune.Le siège socia] de la comp'gnic est à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Doivii.i.k.15440-o 1486-60 Continental Maintenance Inc.Notice is given that under Part I «»f the Companies Act.letters patent, bearing' date the 29th day of April.1900.have been issued by the Lieutenants Jovcrnor of the Province, incorporating: Lucien Lcmicux, representative.1763 Boisvert, Laval, William Lemelin, organiser, 15 Ste-Anne, P«)inte-aux-Trembles, and Danielle Turcotte, secretary, fille majeure.2020 Nicolet, Montreal, for the following purposes: To carry on business cleaning, washing and installing blinds ami double windows, under the name of \"Continental Maintenance Inc.\", with a total capital stuck t>f 820.000.divided into 20.000 common shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440 1486-6(1 D.C.S.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé «les lettres patentes, en «laie «lu 28e jour «l'avril 1066, «\u2022«instituant en corporation: Irving I.Finkell>erg, avocat, 652, avenue Outremont.Oulremont, John L.Liberman.avocat, 74s7.chemin Spring.( ote-St-Luc.et Norafa D'Abreau.secrétaire, célibataire, 3488, rue Durocher, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie de placements, sous le nom «le « 1).C.S.Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1.000 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le 81 chacune.20.000 actions privilégiées catégorie « A » «l'une valeur au pair «le 81 chacune et 19.000 actions privilégiées catégorie « B » «l'une valeur au pair «le 81 chacune.Le siège social de la compagnie est 4032.Kent.Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-sccrétairc de la province.Raymond Douvillb.15440 170K-00 D.C.S.Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing «late the 26th day of April.1066, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorpo rating: Irving I.Finkelberg, advocate.652 Outremont Avenue.Outremont, John L.Lib*-: man, advocate.74S7 Spring Roa«l, Cote-St-Lui.ami Norah D'Abreau, secretary, spinster.3488 Durocher Street.Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"D.C.S.inc.\".with a \"t«)tal capital stock of 840,000.divided into 1.000 common shares of a par value of SI each, 20.000 class \"A\" preferred shares of a pat value of 81 each and 19.000 class \"B\" preferred shares of a par value of 81 each.The hca«l office of the company is at 4632 Kent.Montreal, judicial district of Montreal.Raymond DOUVILLK, Assistant Secretary of the Province.15440-o 1768-00 Jean des Bois inc.Jean des Bois inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première purtie de la Ixu des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé «les lettres patentes, en «late «lu 2»k' jour «l'avril 1066, constituant en corporation: Jacques Duquette, avocat, 11, rue St-Paul ouest.Guy Godard, avocat, 7A.rue Tour «lu Lac, et Liliane Piché, secrétaire, fille majeure, 65, rue St-Joseph, tous trois de Ste-Agathe-des-Monts, pour les objets suivants: Industrie et commerce «lu bois, sous le nom «le « Jean des Bois inc.».avec un capital total «le 810.000, divisé en 2.000 actions ordinaires «le 810 chacune et en 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, lx-aring «late the 26th day of April.1966.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacques Duquette, lawyer.11 St-Paul Street West, Guy Godard, lawyer, 7A Tour du Luc Street, and Liliane Piché, secretary, fille majeure.65 St-Joseph Street, all three of Ste-Agathe-des-Monts.for the following purposes: The industry ami business dealing of wood, under the name of \"Jean des Bois inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each ami into 2,000 preferred shares of $10 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Aune 11, 10t)C, Vol.OS, So.23 3173 l.c siège social do lu compagnie est à Lac l'Orignal, St-Agrieolc, district judiciaire de Tcrrc- liotme.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dot ville.I5440-O 1744-66 A.ft* Drouin & (ils limitée A.N.Drouin & Son Limited Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi dee compagnies, le lieutenant-gouverneur ration: Aurèlc-X.Drouin, industriel, Geneviève Dumont, ménagère, épouse contractuellemenl séparée de biens dudit Aurèle- V Drouin, tous deux de 570, 3e Avenue, et Serge-R, Drouin, industruel, 799, avenue Dion, Ions trois de \\'al-d'Or, pour les objets suivants: Exercer des commerces de manufacturiers, cmbouteOleurs, importateurs, exportateurs, distributeurs et vendeurs de toutes sortes de breu-Bges non-intoxicants et non-alcoolisés, sous le nom de «A.X.Drouin & fils limitée\u2014A.\\.Drouin & Son Limited»» avec un capital total île $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune.300 actions privilégiées classe «A» de SI chacune et en 1,070 acrions privilégiées classe « B » de 810 chacune.l.c siège social de la compagnie est 1335, chemin Sullivan, Yal-d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Le Sous-sccrétairc de la province.R a y mon i) DoU villk.I.VUO-o 1377-00 C.J.Dryden Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de mars 1000, constituant en corporation: William Dryden, administrateur, Patricia Griffiths, ménagère, épouse séparée de biens dudit William Dryden, Ions deux de 170, des Marguerites, Herbert ( Hivier, administrateur, et Margaret Y.Milmine, ménagère, épouse séparée de biens dudit Herbert Olivier, ces deux derniers de 30 avenue Watt, tous quatre de Châteauguay, pour les objets suivants: Exercer des affaires comme entrepreneurs et faire le commerce de construction mécaniques, comprenant travaux de plomberie, de chauffage et de ventilation, sous le nom de « C.J.Dryden Co.Ltd.», avec un capital total de $27,000, divisé en \">00 actions ordinaires de 810 chacune, 200 actions privilégiées catégorie « A » de $100 chacune et 200 actions privilégiées catégorie B » de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 170, avenue des Marguerites, Châteauguay, district judiciaire de Mean ha mois.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440 1298-00 The head office of the company is at Orignal Lake, St-Agricole, judicial district of Tern bonne.Raymond Douvillk.Assistant Secretari/ of the Proiiuee.15410 1711-00 A.V Drouin & fils limitée A.N.Drouin & Son Limited Xotice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 31st day of March, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Aurèle-X.Drouin, industrialist, Geneviève Dumont, housewife, wife contractually separate as to property of said Aurèle-\\.Drouin, both of 676, 3rd Avenue, and Serge-R.Drouin, industrialist, 799 Dion Avenue, all three of Yal-d'Or, for the following purposes: To carry on the businesses of manufacturers, bottlers, importers, exporters, distributors ami vendors of all kinds of non-toxic and nonalcoholic beverages, under the name of \"A.X.Drouin & fils limitée \u2014 A.X.Drouin & Son Limited\", with a total capital stock of 810,000, divided into 200 common shares of 8100 each, 300 class \"A\" preferred shares of 81 each and 1,070 class \"B\" preferred shares of 810 each.The head office of the company is at 1336 Sullivan Road, Yal d'Or, judicial district of Abitibi.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.16440 1377-00 C.J.Dryden Co.Ltd.Xotice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of March, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: William Dryden, executive, Patricia Griffiths, housewife, wife separate as to property of the said William Dryden, both of 170 des Marguerites, Herbert Olivier, executive, and Margaret Y.Milmine, housewife, wife separate as to property of the said Herbert Olivier, the latter two of 30 Watt Avenue, all four of Châteauguay, for the following purposes: To carry on the business of contractors and to deal in mechanical construction including plumbing, heating and ventilating processes, under the name of \"C.1.Dryden Co.Ltd.\", with a total capital stock of 827,000.divided into 500 common shares of 810 each, 200 class \"A\" preferred shares of 8100 each and 200 class \"B\" preferred shares of 810 each.The head office of the company is at 170 des Marguerites Avenue, Châteauguay, judicial district of Beauharnois.Raymond Douvillk, Assistant Secretari/ of the Province.1Ô440-o 1298-66 E.B.S.construction ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour d'avril 1900), constituant en corporation: René Bcauchamp, électricien, 127, rue Pasteur, Montréal, Guy Hcauchamp, gérant, St-Placide, et Germain Beau- E.B.S.construction ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 12th day of April, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: René Bcauchamp, electrician, 127 Pasteur St., Montreal, Guy Bcauchamp, manager, St-Placide, and Germain Bcauchamp, photo- 3174 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEIIEC, Il juin 1900, 98' année, n° 23 champ, photographe, 155, 4e avenue, St-Eusta-che, pour les objets suivants: Ptlre affairai comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « E.11.S.construction ltée », avec un capital total de S40.000, divisé en 400 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à St-Eusta-chc, district judiciaire de Terrcl>onne.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440-o 1402-00 Let Entreprises Perma inc.The Pcrma Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour d'avril 1900, constituant en corporation: André Duceppc, avocat, 5599, Gatincau, Montréal, Aline Fiset, 950, Sherbrooke est, Montréal, et Rolande Cha-pleau, 43, Deschamps, Lanoraic-d'Autray, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Faire le commerce de meubles et nouveautés de toutes sortes, sous le nom de « Les Entreprises Perma inc.\u2014 The Perma Enterprises Inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440-o 1244-60 grapher, 155, 4th Ave., St-Eustache, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"E.II.S.construction ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at St-EnGaelic, judicial district of Tcrrelxmnc.Raymond Douvillk.Assistant Secretari/ of the Provinr, 15440 M02 ¦\u2022.I .es Entreprises Perma inc.The Perma Enterprises Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, licaring date the 12th day of April, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorpo.rating: André Ducep|k\\ advocate, 5599 Gati.neau, Montreal, Aline Fiset, 950 Sherbrooke St.East, Montreal, and Rolande Chapleau, 43 Deschamps, Lanoraie-d'Autray, the latter two secretaries, filles majeures, for the following purposes: To carry on the business of furniture and novelties of all kinds, under the name of \"Lea Entreprises Perma inc.\u2014 The Perma Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $40,000, di\\ i-ded into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at Mon real, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440 1244-66 The Fast Order Centre Inc.Le Centre des commandes rapides inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour d'avril 1900.constituant en corporation: Murray B.Spiegel, avocat.63, rue Banstcad, Montréal Ouest, Harvey M.Cooperstone.avocat.144S, Beverley Crescent.Laval, et Christine W.Gates, secrétaire, célibataire.2255.rue St-Mathieu, app.1001.Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises fabriqués en tout ou en partie de cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textile, sous le nom de «The Fast Order Centre Inc.\u2014 I.e Centre des commandes rapides inc.», avec un capital total de $40.000.divisé en 15,000 actions ordinaires de $1 chacune et 2.500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.15440 1X05-00 Fidelity Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour de mars 1966, autorisant la fusion de la compagnie « Fidelity Holdings Inc.», constituée en corporation par lettres patentes datées du 10e jour de mai 1955.la compagnie « Gurson Homes Corporation », constituée en corporation par lettres patentes datées du L6e jour de décembre 1953, et la compagnie The Fast Order Centre Inc.Le Centre des commandes rapides inc.Xotice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 28th day of April.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Murray B.Spiegel, advocate.03 Banstead Street, Montreal West.Harvey M.Cooperstone advocate.1448 Beverly Crescent.Laval, ami Christine W.Gates, secretary, spinster.225.'» St.Mathieu Street, apt.1001, Montreal, for the following purposes: To deal in all kinds of products, articles ami merchandise made, in whole or in part, of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, under the name of \"The Fast Order Centre Inc.- Le Centre des commandes rapides inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 15.000 common shares of $1 each and 2,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretari/ of the Province.15440-0 1805-66 Fidelity Holdings Ltd.Notice is given that under Part 1 of the ( 'ompanies Act, letters patent 1 >earing date the 29th day of March, 1900».have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, autortsing the amalgamation of \"Fidelity Holdings Inc.\".incorporated by letters putent dated the 10th day of May, 1955.\"Garson Homes Corporation', incorporated by letters putent dated the 10th day of December, 1053.and \"Dorval Holdings Inc.\".incorporated by QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Aune 11, 10iU>, Vol.OS, So.23 31 To 3 |)i)i\\iil Holdings Inc.», constituée en corpora-limi DAT lettres patentes datées du Hic jour «le ¦eplembr* 1 *.*57, toutes telles lettres patentes a\\.ni été émises en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, pour les objets suivants: I \\créer le commerce d'iUM compagnie d'im-ine!jblea( constmetion et placements, sous le nom de (' Fidelity Holdings Ltd.\\ avec un capital total de 1600,000, divisé en 2,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de 1100 chacune et 25,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de ski chacune.|,c siège social de la compagnie est 2102.rue i lier, dans la cité de Dorval.district judiciaire de Montréal.Le Soiis-seerétuirc de In province.Raymond Douvillk.15440 1470-00\u2014 1320/30 Flexhcton Limited Flexhéton limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la l.\"i des compagnies, le lieutenant-g uverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour d'avril 1066, constituant en corporation: William T.H.Clark, administrateur, 11, Woodiïdge, Beaconsfield, Alfred Ci.Hoffman, ingénieur, 0421.Concourt, et Roger Laliberté, représentant de ventes, 7701.Yves-Prévost, ces deux derniers d'Anjou, pour les objets suivants: l'aire le commerce de toutes sortes de produits et matériaux pour la construction, sous le nom \u2022 le « Flexlieton Limited \u2014 Flexhéton limitée avec un capital-actions divisé en 5.000 actions ordinaires sans valeur au pair et 1.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 220 chacune.Le siège social de la compagnie est à Dominion Industrial Building St-Pierre.district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.15440 1021-00 letters patent dated the 10lh day of September, 1957.all such letters patent having heeli issued under the said Part I of the Companies Act.for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and Investment company, under the name of \"Fidelity Holdings Ltd.\".with a total capital stock of 1500,000, divided into 2,500 preferred shares of a par value of $100 each and 25,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the new company is at 2102 Chattier Street, in the city of Dorval.judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the I'rovince.15-HO-o 1476-68 1330(30 Flexhéton Limited Flexhéton limitée Notice is given that under Part 1 of the Companies Act.letters paient, hearing date the 19th day of April.1066, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: William T.II.Clark, executive, 14 Woodridge, Beaconsfield, Alfred G.Hoffman, engineer.0421 Concourt, and Roger Laliberté, sales representative, 7701 Yves-Prévost, the latter two of Anjou, for the following purposes: To deal in all kinds of building products and construction materials, under the name of \"Flexlx'ton Limited \u2014 Flexhéton limitée\", with a capital stock divided into 5.000 common shares without par value and 1,000 preferred shares of a par value of $20 each.The head office of the company is at Dominion Industrial Building, St-Pierre.judicial district of Montreal.Raymond Dot villi;.Assistant Secretari/ of the Proiinre.15440-41 1021-00 André Fortin service station inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-B .uverneur de la province a accordé des lettres [latentes, en date du 31e jour de mars 1900.constituant en corporation: Claude Lefebvre, Pierre Paquin.tous deux avocats, de 1050, des l.aurcntides.Laval, et Cécile Basque, secrétaire, veuve non remariée de Paul Founder.3089, Bossuet, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'automobiles et faire affaires comme garagistes, sous le nom de * André Fortin service station inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2.000 actions ordinaires de 810 chacune et en 2,000 actions privi-égjées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Laval, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.15440m 1388-60 Foyer Jeannc-Mancc Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le licutcnnnt-gimverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour d'avril 1900, ¦oustHuant en corporation sans capital-actions: Paul-Êmile Cliche.10, Agnès.Kvaristc Roy, 2, André Fortin service station inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of March.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Claude Lefebvre, Pierre Paquin.both advocates, of 1050 des Laurcntidcs.Laval, and Cécile Basque, secretary, unremarried widow of Paul Founder, 3089 Bossuct.Montreal, for the following purposes: To carry on business dealing in automobiles, and to act as garagemcn.under the name of \"André Fortin service station inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2.000 common shares of $10 each and 2.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Laval, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretary if the Province.15440 1388-61) Foyer Jeanne-Mance Notice is given that under Part III of the Companies Act.letters patent, bearing date the 20th day of April.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation Without share capital: Paul-Kinilc Cliche.10 Agnès.Kvaristc Roy.2 3170 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 11 juin I960, 98' année, n° 23 Lévis, J.-Léo Bluil, 203, Laval, tous trois industriels, René Pure, opérateur, 55, Salabcrry, Joseph-C.Roy, garagiste, 187, Laval, Joseph Huot, 37, r'rontcnac, Alhiny (îoulet, 72.Villeneuve, Laval Portier, 112, Dollard, Claude Bëchardj 84, Agnès, tous quatre marchands, Joseph Lacroix, contremaître.45, Notre-Dame, Aristide Rohcrgc.7, Millettc, Alfred Hrfilotte.57, Agnès, tous deux rentiers, Clément Martel, courtier «rnssurnnoes, 2til, Laval, Fernaml Belleueur, 97, Papineau, Ju«-(pics Lachance, 88, Choquette, tous deux fonctionnaires, et lingues Pan-liteau, entrepreneur, 10\").Agnès, tous seize de Luc-Mt'-gunl ic, pour les objets suivants: Administrer et diriger une institution de bien-être en lu municipalité de Lac-Mégantic, sous le nom de « Foyer .Icanne-Mance ».Le montant auquel sont limités les biens im- mobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de 1300,000.Ia* siège social de la corporation est à Lac-Mégantic.district judiciaire de Bcauce.Le Sons-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.15440-c 5137-65 Canin automobiles inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour «l'avril 1066, constituant en corporation: Réjane Laberge, épouse séparée «le Liens «l'Emile Colas, 25.chemin «le Casson, West mount, Claude-E.Leduc, 105, avenue Beverley.Mont-Royal, et .lean Lefrancois, 101, Maple\\voohis.trialists, René Paré, operator, 55 Salabcrry.loseph-C.Roy, garagemen, 187 Laval, Joseph Huot, 37 Frontenac, Alhiny (îoulet, 72 \\ illc neuve, Laval F«>rticr, 142 Dollard, Claude Béchard, 84 Agnès, ail f«>ur traders, Joseph Lacroix, foreman, 45 Notre-Dame, Aristide Roherge.7 Millettc.Alfred Brûlotte, 57 Agnès, both annuitants.Clément Martel, insurance broker, 201 Laval, Pcruund Bellelleur, 97 l'api-ueaii, Jacques Lachance, 3.3 Chotpictte.Iinlh civil servants, and lingues Parcnteuu.contractor, 10.\") Agnès, all sixteen of Lac-Mégantic.for the following purposes: To manage and direct a social welfare institution in the municipality of Lac-Mégantic, under the name t>f \"Foyer Jeanne-Mam e\".The amount to wliieh are limited the immoveables which the corporation may acquire and possess, is 8200,000.The head office of the corporation is al I ;u-Mégantic, judicial «listrict of Beauce.Raymond Douville, Assistant Secretari/ of the Province.15110 5137-65 Garon automobiles inc.Notice is given that under Part I «>f tlie Companies Act.letters patent, bearing «late the 27th day of April, 1900, have been issued by I lie Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Réjane Labergc, wife separate so I\" projK'rty of Emile Colas, 25 «le Casson Road, West mount, Claude-E.Leduc, 105 Beverley Avenue, Mont-Royal, ami Jean Lefrancois.191 Maplcwood, Outremont, all three lawyers.for the following purposes: To deal in motor véhicules and to carry on business as garagemen.umler the name «>f \"Garon automobiles inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and into 000 preferred shares of $100 each.The head office «>f the company is at Lschute, judicial «listrict of Terrebonne.Raymond Douvillk.Assistant Secretari/ of the Province.15440 1757-66 Giuseppi Restaurant Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, l)earing «late the 5th day of May, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Giuseppe Salvaggio, restaurant owner.2142 Vauquelin, Montreal, Edward J.Faillaee.salesman, 254 Place «le Bullon, Boucherville, and David Sciortino, builder, 220 Monseigneur Char bonneau, Boucherville, for the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, under the name of \"Giuseppi Restaurant Inc.\", with a total capital stock of $30,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Boucherville, judicial district of Montreal.RAYMON d DOU villk, Assistant Secretary of the Province.15440-o 1921-00 Glenhar Construction Co.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of April, 1966, have been issued by the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, IMG, Vol.00, No.93 3177 puttiiIc-s, en date du 27e jour d'avril 1900, OOnsIit liant en corporation: Felice Jlosenstcin, ménagera, épouse séparée de biens de Issic Oaron, et dûment autorisée par ce dernier aux (in- del présentes, f)729, avenue I/ukwood, H.Laddic Schnuil>erg, avocat, 7400, chemin Kings-ley, tous deux de Côte-St-Luc, et Ginette Leroux, secrétaire, célibataire, 30, rue Vermont, Jacques-Cartier, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compugnie de construction, sous le nom de « Glenhar Construction Co.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune cl 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.I,e siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440 1779-00 Hôtel Mont-Valin (1966) ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant\" gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour d'avril I860, constituant en cor|>oration: Armand Couture, «utrepreneur.Dame Armand Couture, ménagère, épouse COntractuellement séparée de biens dudit Armand Couture, et d muent autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de 239, rue Talon.Chieouthni-Xord.et Craig Murdoek.entrepreneur, chemin Sydenham.Chicoutiini.pour les objets suivants: Faire affaires comme hôteliers, sous le nom de Hôtel Mont-Valin (1900) ltée ».avec un capital total de 8100.000.divisé en 3.000 actions classe A » de $10 chacune, 3,000 actions classe « R » ¦ le $10 chacune et en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Ix' siège social de la compagnie est à Chicoutiini.district judiciaire de Chicoutiini.Le Sous-sccrétairc de la prorince, R aymon d douvi lus.I5440-O 1620-66 Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Felice Rosenstein, h usewife, wife separate as to property of Issie Caron, and duly authorized by him for the purpose of these presents, 5729 Lockwood Avenue, II.Laddie Schnai-bcrg, advocate, 7400 Kingsley Road, both of Côte-St-Luc, and Ginette Leroux, secretary, spinster, 30 Vermont Street, Jacques-Curtier, for the following pur|>oses: To carry on the business of a construction company, under the name of \"Glenhar Construction Co.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440-o 1779-OG Hôtel Mont-Valin (1966) ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of April.1900.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Armand Couture, contractor.Mrs.Armand Couture, housewife, wife contractually separate as to property of said Armand Couture, and duly authorized by him for the presents, both of 239 Talon Street.Chieoutimi-North, and Craig Murdoch, contractor, Sydenham Road.Chicoutiini, for the following purposes: To carry on business as innkeepers, under the name of \"Hôtel Mont-Valin (1900») ltée\".with a total capital stock of $100.000.divided into 3.000 class \"A\" shares of $10 each.3.01 0 class \"B\" shares of $10 each and into 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Chicou-timi.judicial district of Chicoutiini.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440 1620-66 I.N.T.Import Ltd.Importations I.N.T.ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé des lettres patentes, en date du 22e jour d'avril 1966, constituant en corporation: Charles Forget.290.Des Alouettes, Laval, Pierre Lemire, 12405, S te-Catherine est, Pointe-auz-Trembles (Ile-dc- Montréal), et René Dcsrechcs, 2330, Théodore, Montréal, tous trois vendeurs, pour les objets suivants: Faire l'importation et l'exportation de tous produits, articles et marchandises en général, sous le nom de « I.N.T.Import Ltd.\u2014 Importations I.N.T.ltée », avec un capital total de S40.000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 2330.Théodore, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440-o 1701-66 Les Immeubles Radine inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres I.N.T.Import Ltd.Importations I.N.T.ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 22nd day of April.1906.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Charles Forget.296 Des Alouettes.Laval, Pierre Lemire, 12405 Stc-Cathcrine East, Pointe-aux-Trembles (Island of Montreal), and René Dcsroches, 2330 Théodore.Montreal, all three salesmen, for the following purposes: To import and cx|x>rt all products, articles and merchandise in general, under the name of \"I.N.T.Import Ltd.\u2014 Importations I.N.T.ltée\", with a total capital stock of $10.000.divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at 2330 Théodore, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dor villk.Assistant Secretary of the Province.15440 1701-00 Les Immeubles Radine inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of April, 1966, have been issued 3178 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 11 juin 1966, 98* année, n° 23 pttentel, eu date «lu 20e jour «l'avril 19(10, constituant en corporal ion : .Murray Lapin, avocat et «'otiseil eu Loi «le la reine, 107, chemin Edgchill, Westinount, Harold Ih-rmcr, avocat, ¦17, White Pine Drive, Hcuconsficld, et Shirley Muggcridgc, Secrétaire, fille majeure, 912, avenue Polluer, Brossard, |M>ur les objets suivants: Kxercer le commerce «l'une compagnie d'im-incuhles, const ruction cl placements, sous le nom «le « Les Immeubles Jtadiue inc.\u2022>, avec un tnpital total de 140,000, «livisé en 20,000 acti.ms ordinaires «l'une valeur au pair de SI chacune et 20,000 actions privik'-giées «l'une valeur nu pair «le SI chacune.Le siège social «le la compagnie est 1265, carré Phillips, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440 1071-00 Immeubles Sirois inc.Avis est donné Qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en «late «lu 15e jour d'avril 1900, constituant en corporation: Jules-Roch Sinus, marchand, Edith Lomieux, ménagère, épouse commune en biens dudit .Iules-Boch Sirois, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de St-Jén>me-de-Matane, et Lucille Lcmicux, secrétaire, fille majeure, 33, rue St-Pierrc, Matane, pour les objets suivants: Faire affaires «lans les domaines de l'immeuble et «le la «construction, sous le nom de « Immeubles Sirois inc.», avec un capital total «le $100,000, «livisé en 500 actions ordinaires de §100 chacune et en 500 actions privilégiées «le $100 chacune.Le sit'-gc social «le la compagnie est a Matane, district judiciaire de Rimouski.Le Sou.s-secrétaire de la province, Raymon d Douvillk.15440-0 1544-00 Les Immeubles Sorel ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes, en date «lu 26e jour d'avril 1900.constituant en corporation: Réjane Laberge, épouee séparée de biens «le Emile Colas, 25.chemin «le Cusson, Wcstmouut, Claude-E.Leduc.105, avenue Beverley, Mont-Royal, et Jean Lefrançois, 191.Maplcwood.Outremont, tous trois avocats, pour les objets suivants: Paire affaires «lans les domaines de l'immeuble «\u2022t «le la construction, sous le nom «le « Les Immeubles S»»r«'l ltée », avec un capital total «le S10.000.«livisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district jiuliciairc «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440*0 1710-00 Jaberson Trading Ltd.Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé des lettres patentes, en date «lu 25e jour d'avril 1900, constituant en corporation: Jack Lighstone, avocat, 2170, chemin Fulton, Mont Royal, Jacob L.Rothman, avocat, 7920, chemin Kingsley, by the Lieutenant-Governor of the Province, Incorporating! Murray Lapin, advocate and Queen's < ounsel, 107 Edgchill Road, Westmount Harold Dernier, advocate, 47 White Pine Drive, Reneonsfiehl, ami Shirley Muggeridgc, secretary, spinster of the full age of majority, 942 Potliier Avenue, Rrossard, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction ami investment company, under the name of \"Les Immeubles Radine Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of the par value ol si each and 20,000 preferred shares of the par value of $1 each.The head oflicc of the company is at 1255 Phillips Square, Montreal, judicial district of Montreal, Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Pros tno .15440-o 1671-66 Immeubles Sirois inc.Xotice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of April, 1900, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jules-Roch Sirois, trader, Edith LemieUX, housewife, wife common as to properly «>f said Jules-Roch Sirois, ami duly authorized by him for the presents, both of St-Jcn>mc-dc-Malane, and Lucille Lemieux, secretary, fille majeure, 33 St-Pierre Street, Matane, for I lu-following purposes: To carry on business in the real estate and construction fields, under the name of \"Immeubles Sirois inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 500 common shares of $100 each and into 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Matane, judicial district of Rimouski.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440 1544-66 Les Immeubles Sorel ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date 11 \u2022 * -20th day of April, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Réjane Laberge, wife separate as to pre jH-rty «)f Emile Colas.25 de Casson Road.We-i mount, Claude-E.Leduc, 105 Beverley Avenu*.Mont-Royal, and Jean Lofrnncois, 191 Maple wood, Outremont, all three lawyers, for th following purposes: To carry on business in the real estate and construction fields, under the name of \"Lea Immeubles Sorel ltée\", with a total capital stock of $10.000.divided into 1.000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Mont real, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretari/ of the Province.15440 1716*66 Jaberson Trading Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of April, 1966, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jack Lightstone, advocate, 2176 Fulton Road, Mount Royal, Jacob L.Rotlunun.advocate, 7920 Kingsley Road, Côte-St-Lue. QUEBEC! OFFICIAL GAZETTE, Aune II, 1960, Vol.98, No.28 3179 Cot St-Luc, et Aimé Durunlcau, huissier, 183, ; rUC Ste-( 'utherine, Montréal, pour les objets mu» ants: i lin- le commerce de toutes sortes de tutlui ,i pr iduita d'iceux, fabriquée en tout ou en partir, de laine, coton, rayonne, nylon, et autres fibre» naturelles ou synthétiques ou combinaison ,l i,.lies, mue le nom de « Jabenon Trailing I.i.l.avec un capital total de SoO.OCO, divisé , i 1,000 actions ordinaires de $10 chacune, 1,01 0 actions privilégiées, catérorie « A » de $10 iune et 100 actions privilégiées catégorie « B de $100 chacune.I,c >iègc social de la compagnie eit 55, ouest, avenue Slont Royal, Montréal, district judiciaire Montréal.Le Sous-sccrétairc de la province.Raymond Dor villk.15440 1719-00 Kcntly Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première parlie de la lx>i «les compagnies, le liciitenant-\u2022Miiivcrncur «le la province a acconlé «les lettres patentes, en date du 20e jour d'avril 1900.constituant en corporation: John I,.Liberman, avocat, 7ls7, Spring Road, Cdte-St-Luc, Irving I.Finkelberg, avocat, 052, avenue Outremont, Outremont, et Xorah D'Abreau, secrétaire, fille majeure, 3488, rue Durocher, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie d'immeubles, «le construction et «le placements, sous li- nom de « Kentlv Realties Inc.».avec un capital total «le $40,000, «livisé en 10.000 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le SI chacune \\ sous le nom \\ avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Grand' Mère, district judiciaire «le St-Maurice.Le Sous-sccrétairc de la province, RaYMON i) 1 >ou vi li.k.15440-O 1580-00 Laval automate inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date «lu 29e jour «l'avril 1900), constituant en corporation: Robert McDuff, 33, Place d'Argentcuil, Fernand McDuff, 35, Place the 10th day of December, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital; William Nightingale, project director, 187 Cool' breeze Avenue, (Lakeside), \u2022Iacf the said John Bdwin Mitcham, both of 113 Elm Crescent, W.Douglas Laird, engineer, Patricia Hale, hoi, ie.wile, wife of the said W.Douglas Laird, bold of 20058 Lakeshore Road, all lour of Raie-dTriV, Romlall Weitzel Damon, assessor, 127 Km - Road.(Valois), Jacques-Cartier, Gérard Lussier, manager (Dominion Store), 105, 45th Avenue, Lachine, Maric-Franf retarded children and t«» preserve ami pertuate the associations and traditions ol the Vocational Projects Association'*, under the name of \"The Lakeshore Vocational Projects Association Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold or own is to he limited, is $100,000.The head office of the corporation is at Lake-shore Y.M.C.A., 170 St-Louis Avenue, Pointe-Claire, judicial «listrict of Montreal.Raymond DouviLLB, Assistant Secretari/ of the Prosifies.15440-0 5382-65 Laurentide lavage Auto-Mobile inc.Laurentide Mobile Car Wash Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dab the 29th day of April, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province, incorporating: Ixniis-Philippc Lemirc, electrician.1530, 0th Avenue, Viateur Desaulniers, clerk.471, 15th Street, and Gilles Lamarre, insurance broker, 779, 5th Avenue, all three of Grand1 Mère, for the following purposes: To deal in motor véhicules ami to carry on business as garagemen, under the name of \"Laurentide lavage Auto-Mobile inc.\u2014 Laurentide Mobile Car Wash Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $10.1 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Grand' Merc, judicial «listrict of St-Maurice.Raymond Douviixk, Assistant Secretary of the Province.15440 1580-00 Laval automate inc.Notice is given that under Pari 1 of tin-Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of April, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province, incorporating: Robert McDuff, 33 Place d'Argentcuil.Fernand McDuff, 35 Place «l'Argentcuil.both «>f QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, 1966, Vol.98, No.23 3181 dWrgcnleuil, tous deux de Laval, et Jean Coutu, 4828, St-Urbain, Montréal, tous trois industriels, pour lei objets suivants: Opérer le commerce de machines distributrices automatiques, sous le nom de « Laval automate inc.avec un capital total de $40,000, divisé ru 300 actions ordiuuircs de $100 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie est 33, Place d'Argenteuil, Laval, district judiciaire «h- Montréul.ht Sous-secrétaire de la province, Raymond Dor ville.15440m 1785-00 Laval, and Jean Coutu, 4828 St-I'rbain, Montreal, all three industrialists, for the following pur- poses : To operate automatic vending muehincs, under the name of \"Laval automate inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 33 Place d'Argentcuil.Laval, judicial district of Montreal.Raymond Dor ville, Assistant Secretary of the Province.15440 1785-06 Laval emludlissement ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dé la province a accordé del lettres patentes, en «late du 29e jour d'avril 1008» constituent en corporation: Louis Leblanc, courtier en immeubles, 24, Pontmain, Laval, Lucien Roussel, cultivateur, St-Sylvère, et Denise Dumas, sténo-dactylo, tille majeure.7613, St-Denis, Montréal, pour les objets suivants: Paire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Laval embellissement ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Ixi siège social de la compagnie est 7434, rue St-Hubert, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Le Sous-sccrétairc de la province, Raymond Douvillk.i.-.-UO-o 1710-66 Laval embellissement ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 29th day of April, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Louis Leblanc, real estate broker, 24 Pontmain, Laval, Lucien Roussel, farmer, St-Sylvère, and Denise Dumas, stenographer, fille majeure, 7613 St-Denis.Montreal, for the following purposes: To carry on business as general building contractors, under the name of \"Laval embellissement ltée\", with a total capital stock of $40.000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at 7434 St-Hubert, Street, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dor ville, Assistant Secretari/ of the Province.1.5440 1710-00 Laval Hot Bagel Bakery, Grocery & Delicatessen Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 25c jour d'avril 1966, constituant en corporation: Abraham Raruch, gentilhomme, 4937, nu?Curry, David Krell, boulanger, 162, rue St-Jude, tous deux de Laval, et Thehna Stevenson, secrétaire, célibataire, 195, (k' Avenue, St-Eustache, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchandises se rapportant à la boulangerie, boucherie et charcuterie, sous le nom de « Laval Ilot Ragcl Bakery, Grocery & Delicatessen Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Ix?siège social de la compagnie est 4267.boulevard Samson.Laval, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dor ville.15440 1696-66 Laval Hot Bagel Bakery, Grocery & Delicatessen Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing «late the 25th day of April, 1966, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Abraham Raruch.gentleman.4937 Curry Street, David Krell, baker, 162 St.Jude Street, both of Laval, and Thelma Stevenson, secretary, spinster, 195, 6th Avenue, St-Eustache, for the following purposes: To deal in merchandise relating to the bakery, butchery and delicatessen businesses, under the name of \"Laval Hot Ragel Bakery, Grocery & Delicatessen Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 4627 Samson Boulevard.Laval, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretari/ of the Province.15440-o 1696-00 Legault, Gauthier & associés inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour d'avril 1966, constituant en corporation: Pascal Legault, 1301, Jean-Dequen, Ste-Foy, Lucien Gauthier, 1300, Patenaude, Sillery, tous deux courtiers, et Mare \u2022lessop, avocat, 2748, l>oulcvard Liégeois, Ste-Foy, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers et agents en assurance, sous le nom «le « Leganlt.Gauthier Legault, Gauthier & associés inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, 1 tearing date the 26th day of April.1966.have l>ecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pascal Legault.1301.Jean-Dequen, Ste-Foy.Lucien Gauthier, 1300 Patenaude, Sillery, lioth brokers, and Marc Jessop, advocate, 2748 Liégeois Blvd., Ste-Foy, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers an«l agents, under the name of \"Legault, Gauthier & GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 11 juin 1906, 98' année, u° 28 & associés inc.», avec un capital total de $10.000, divisé en -1.000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 2007.l>oulevard Sir Wilfrid-Lauricr.Ste-Foy, «listrict judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la province, raymond Douvillk.15440-o 1769-66 Lorinco inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé des lettres patentes, en date du 22e jour «le mars 1900, constituant en «corporation: Yves Laurin, Luc I.au ri n.tous deux administrateurs, de 21, rue St-Paul est, et Jean-Paul Ste-Marie, avocat, 70S, Sherbrooke ouest, app.2, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire alFaires comme grossistes ou détaillants «le tous produits de consommation ou d'utilités personnelles, sous le nom de « Lorinco inc.», avec Un capital total de $40,000, «livisé en 100 actions ordinaires «l'une valeur nominale «le $100 chacune et en 300 actions privilégiées «l'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440-o 1211-66 associés inc.\", with a total capital stock of 140,000, divided into 4.000 common share- of 810 each.The head office of the company is at 2007 Sir Wilfrid-Laurier Blvd., Ste-Foy, judicial district of Quebec.Raymond Douvillk, Assistuut Secrclaru of the Province, 15440 1769-68 Lorinco inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of March, 1900.have !>een issued by I he Lieutenant-Governor f the Province, incorporating: Yves Laurin, Luc Laurin, both directors, 21 St-Paul Street Fast, and Jean-Paul Ste-Marie, lawyer, 70S Sherbrooke West, Apt.2, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as grocers or retailers of all consumer or personal utility products, under the name of \"Lorinco inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a nominal value of $100 each and into 300 preferred shares of a nominal value «>f 8100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440 1211-liO Loucam Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1900, constituant en corporation: Louis Rivard, sous-officier de l'Aviation Royale du Canada, St-Adolphe-d'Howard, (Lac-St-Dcnis), Jacqueline Laliberté, secrétaire, fille majeure, 5609, rue Yiau, Montréal, et Bernard-E.Blanchard, avocat, 105, 3e avenue su«l, Roxl>oro, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom «le « Loucam Co.Ltd.», avec un capital total de $100,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune, 200 actions privilégiées classe « A » de $10 chacune et en 390 actions privilégiées classe « B » de $200 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.15440-o 1775-66 M.F.C.Associates Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé des lettres patentes, en date «lu 26e jour d'avril 1966, constituant en corporation: William F.O'Carroll, consultant, Michael W.O'Carroll, comptable, tous deux de 5718, Wolsley, Côte-St-Luc, George P.Mentis, vendeur, et Helen Mentis, ménagère, épouse dudit George P.Mentis, ces deux «lerniers de 1340, Kli/ahelh.St-Laurcnt, j)our les objets suivants : Agir en qualité «le consultant dans l'embauchage de personnel et de services connexes, sous le nom de « M.F.C.Associates Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1.000 actions Loucam Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 29th day of April, 1966, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Louis Rivard, non-commissioned officer of the Royal Canadian Air Force, St-Adolpiie-d'Howard, (Lac-St-Dcnis), Jacqueline Laliberté, secretary, fille majeure, 5609 Yiau St., Montreal, and Bernard-E.Blanchard, advocate, 105, 3rd Ave.South, Roxboro, for the following purposes! To carry on business as builders ami general building contractors, under the name of \"Loucam Co.Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divkled into 200 common shares of $100 each, 200 preferred class \"A\" shares of $10 each and 390 preferred class \"B\" shares of 8200 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.15440 1775-00 M.F.C.Associates Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of April, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: William F.O'Carroll.consultant.Michael W.O'Carroll.accountant, both of 5718 Wolsley, Côtc-St-Luc, George P.Menti-, salesman, ami Helen Mentis, housewife, wile of -the said George P.Mentis, the latter two «>l 1340 Elizabeth, St-Laurent, for the following purposes: To act as consultant in the placing of personnel and allied services, under the name of \"M.F.C.Associates Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, 1906, Vol.98, No.28 3183 ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privi> légiées «le $10 chacune.Le siège social de lu compagnie est 1454, rue Mountain, suite 400, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, RAYMOND Douville.15440 1413-00 $10 each ami 3.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1454 Mountain Street, Suite 400, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440-o 1413-00 Menuiserie Joliettc inc.\\vis est donné qifen vertu de lu première partie de lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentee, en date du 20e jour d'avril 1900.constituant en corjMirnt ion : Pierre Wilhrod Gauthier, 74.avenue Kelvin, Outremont, Pierre Legrand, 415.Place d'Amiens.Laval, Jacques Laurent, 195.rue Marcotte, St-Laurent, et Bernard André Roy, 2090, rue Claremont, Montréal, tous quatre avocats, pour les objets suivante: Paire affaires comme entrepreneurs généraux \u2022 n menuiserie, sous le nom «le « Menuiserie loliette inc.», avec un capital divisé en 120 allions ordinaires sans valeur nominale et en _n0 actions privilégiées d'une valeur nominale de s 100 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Sept-lles.«listrict jiuliciairc «le Hauterive.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.i5440-o 1634-00 Menuiserie Joliette inc.Notice is given that Under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing «late the 20th day of April, 1900.have been issued by the Lieutenant-Governor «»f the Province, incorjM)-rating: Pierre Wilbrod Gauthier, 74 Kelvin Avenue, Outremonl, Pierre Legrand, 415 Place «l'Amiens, Laval.Jactpies Laurent.195 Marcotte Street.St-Laurent.ami Bernard André Roy.2096 Claremont Street, Montreal, all four lawyers, for the following purposes: To carry on business as general carpentry contractors, under the name of \"Menuiserie Joliette inc.\", with a capital stock divided into 120 common shares without nominal value and into 280 preferred shares of a nominal value of $100 each.The hea«l office «>f the company is at Sept-Ih's.judicial district of Hauterivc.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.15440 1 634-66 Metropolitan Growth Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour d'avril 1966, constituant en corporation: Rico Ellmenreich administrateur, Caria Ellmenreich, ménagère, «:l>ouse dudit Rico Ellmenreich, tous deux de 7431, chemin Kingsley, Côte-St-Luc, Henry Sclirciber, administrateur, 263, chemin Beacons-liehl, Beaconsfield, et Louis Schreibcr, administrateur, 4341, avenue Westmount, Westmount, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de « Metropolitan Growth Corporation », avec un capital total de *40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $1 chacune et 36,000 actions privilégiées de $1 '\u2022hacune.Le siège social de la compagnie est 54S5 ouest, rue Sherbrooke, suite 208, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.15440 1628-66 Metropolitan Growth Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, l>earing date the 19th day of April, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Rico Ellmenreich, executive, Carla Ellmenreich, housewife, wife of the said Rico Ellmenreich, both of 7431 Kingsley Road, Côte-St-Luc, Henry Schreiber, executive, 263 Beacons-field Road, Beaconsfield, and Louis Schreil>cr, executive, 4341 Westmount Avenue, Westmount, for the following purposes.To carry on the business of an investment company, under the name of \"Metropolitan Growth Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $1 each and 36,000 preferred sliares of $1 each.The head office of the company is at 5485 Sherbrooke Street West, Suite 208, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.15440-o 1628-66 John Meunier inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour d'avril 1966, constituant en corporation: Pierre Legrand, 415, Place d'Amiens, Laval, Louis-Yves Fortier, 40, avenue Arlington, Westmount, et Jacques Laurent, 195, rue Marcotte, St-Laurent, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en plom-herie, chauffage et traitement d'eau, sous le nom de « John Meunier inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 9,800 actions ordinaires John Meunier inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of April, 1966, liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Legrand, 415 Place d'Amiens, Laval, Louis-Yves Fortier, 40 Arlington Avenue, Westmount, and Jacques Laurent, 195 Marcotte Street, St-Laurent, all three lawyers, for the following purposes : To carry on business as plumbing, heating and water softening contractors, under the name of \"John Meunier inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 9,800 common shares 3184 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 11 juin 1906, 98' année, n\" 28 «l'une valeur nominale «le $10 chacune et en 2,000 actions privilégiée! «l'une valeur nominale «le $1 chacune.I^e siège social «le la compagnie est à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire Je la province, Raymond Douvillk.15440-o 1561-00 The Montreal Club of Clothing Foremen and Factory Managers Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie «le la I»i «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé «les lettres patentes, en «late du 26e jour «l'avril 1966, constituant en corj>oration sans capital-actions: Anthony Rodolph Sorrentino, gérant d'usine, 1455, chemin Canora, Mont Royal, Joseph I)i Murro, 7202, rue Lajeunesse, app.3, Joseph Vole-no, 0000, rue Cartier, Roy Laudadio, 4407, rue Fahre, Hyman Moses, 4087, rue Rouchette, et All>ert Rosa, 1040, rue Pasteur, les cinq «1er-niers contremaîtres de Montréal, pour les objets suivants: Stimuler et encourager plus de compétence et d'habilité professionnelles et artistiques chez les gérants et les contremaîtres d'usines «lans l'indus-trie du vêtement, sous le nom de « The Montreal Club of Clothing Foremen ami Factory Managers Inc.».Le montant auquel est limiter la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder ou détenir est «le 8100,000.Le siège social de la corporation est 7202, rue Lajeunesse, app.3, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymon d Dou ville.15440 1734-00 of a nominal value of $10 each and into 2,000 preferred shares of a nominal value of 81 each.The head offiee of the company is at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440 1661.88 The Montreal Club of Clothing Foremen and Factory Managers Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, louring «late lite 20th «lay of April, 1066, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without sahre capital: Anthony Rodolph Sorrentino, factory manager, 1455 Canora Road, Mount Royal, Joseph Pi Murro, 7202 Lajeunesse Street, Apt.3, Joseph Veleno, 6969 Cartier Street, Roy Lsndadio, 4407 Fabre Street, Ilyman Moses, 4687 Bon-chette Street, and Albert Rosa, 1040 Pasteur Street, the latter five foremen, of Montreal, for the following purposes: To promote an«l foster greater professional ami artistic knowledge anil ability among factory managers and factory foremen in the clothing industry, under the name of \"The Montreal Club of Clothing Foremen and Factory Managers Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which may be owned or held by the corporation is to !>e limited, is $100,000.The head of lice of the corporation is at 7262 Lajeunesse Street, Apt.3, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440-o 1734-66 Montreal Dryer Manufacturing Limited Les Fabricants de séeheurs de Montréal limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 26e jour d'avril 1966, constituant en corporation: Raymond Eric Par-sons, 11, chemin DeCasson, Graham Nesbitt, 250, avenue Clarke, tous deux de Westmount, et Clément Fortin, 1240, est, boulevard St-Joseph, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce de machines, machinerie, pièces d'icelles, accessoires, instruments, dispositifs, fournitures, attaches, et outillage, sous le nom de « Montreal Dryer Manufacturing Limited \u2014 Les Fabricants de séeheurs de Montréal limitée », avec un capital total de $210,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Âe Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440 1703-66 Orange Crush St-Jérôme ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de mars I960), constituant en corporation: Jean-Paul Reaulicu, marchand.Georgette Piché.ménagère, épouse Montreal Dryer Manufacturing Limited Ia's Fabricants de séeheurs de Montréal limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of April, 1966, have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Raymond Eric Parsons, 11 DeCasson Road, Graham Nesbitt, 250 Clarke Avenue, botli of Westmount, and Clément Fortin, 1240 St.Joseph Boulevard East, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To deal in machines, machinery, parts thereof, acessories, instruments, devices, supplies, attachments and equipment, under the name of \"Montreal Dryer Manufacturing Limited \u2014 Les Fabricants de séeheurs île Montréal limitée\", with a total capital stock of $210,000, divided into 10,000 common shares of SI each and 20,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440-o 1703-60 Orange Crush St-Jérôme ltée Notice is given that un«lcr Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of March, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Paul Beaulicu, merchant, Georgette Piché, housewife, wife contractually QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, 1966, Vol.98, No.23 3185 ictrnctucllemcnt séparée de biens dudit Jcan-Paul Meaulieu, tous deux de 491, Du Domaine, Si-Jérôme, et Jean-Paul Qucnneville, teelmieien, 11 1(1, Dutrissac, St-Luurent, pour les objets vante: l'aire le commerce d'eaux guzouses et de tous autres breuvages non alcooliques, sous le nom .le «Orange ('rush St-Jérôme ltée >\\ avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S5 chacune et en 950 actions privilégiées «le 8100 chacune.I.e siège social de la compagnie est à Saint-i iVnne.«listrict judieiuire «le Terrebonne.I.e Sous-secrétaire de la province, Kavmono Douvillk.I5440-o 1805-66 separate as to property of the said Jean-Paul BeaulieU, both of 491 Du Domaine, St-Jérôme, ami Jean-Paul Qucnneville, technician, 1140 Dutrissac, St-Laurent, for the following purposes: To carry on business dealing in aerate«l water and in all other non-alcoholic leverages, under the name of \"Orange Crush St-Jérôme ltée\".with a total capital stock of $100,000.divide*! into 1.000 common shares of 85 each ami 950 preferre«l shares of 8100 each.The bead office «»f the company is at Saint- Jérôme, judicial «listrict of Terrebonne.Raymond Dot-villk.Assistant Secretari/ of the Province.16440 1305-00 Ouimet & Poulin Construction Co.Ouimet & Poulin Construction Co.Avis est donné qu'en vertu «le la premiere partie «le la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres [latentes, en «laie «lu 15e jour «l'avril 1900, constituant en corporation! Pierre Legraml, 415, Place «l'Amiens, Laval, Raymond Crevicr, 2930, rue Lacombe, Montréal, et Jacques Laurent.195.rue Marcotte, St-Laurent.tous trois avjx'ats, pour les objets suivants: faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom «le « Ouiincl & Poulin Construction Co.», avec un capital total de $40,000, «livisé en 8,000 actions ordinaires «l'une valeur nominale de 81 chacune «'t en 32.000 a«tions privilégiées d'une valeur nominale de $1 chacune.I/c siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Doi vii.lk.I5440-o 1502-00 Paquin et frère inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé «les lettres patentes, en «late du 12e jour «l'avril 1966, constituant en corporation: Luc Parent.560, avenue Carlylc.Chimie Rélund.2870, avenue Glencoe, tous deux «le Mont-Royal.René-C.Alary, 3345.McCarthy, St-Laurent, tous trois avocats, et Berthe Latontaine, secrétaire, fille majeure, 1050, boulevard St-Joscph est, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme boulangers, sous le nom de « Paquin et frère inc.», avec un capital total de 850,000.«livisé en 300 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune et en 200 actions privil«:giées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à St-Chry->ostôme, district judiciaire de Reauharnois.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.L5440»o 1202-00 Pearson et fils ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en «late du 20e jour «l'avril 1966, constituant en corporation: Emile Pearson, marchand, Roger Pearson, mineur, et Huguette Tremblay, ménagère, épouse eontractuellement séparée de biens dudit Roger Pearson, tous tniis de Chil)ougamau, pour les objets suivants: Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of April.1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Legrand, 415 Place d'Amiens, Laval, Raymond Crcvier.2030 Lacombc Street, Montreal, ami Jacques Laurent.195 Marcotte Street, St-Laurent.all three lawyers, for the following purposes: To carry on business as general building contractors, under the name «)f \"Ouimet & Poulin Construction Co.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 8,000 common shares of a nominal value of 81 each and into 32,000 preferred shares of a nominul value of 81 each.The head office «>f the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Doivii.i.k, Assistant Secretari/ of the Province.15440 1563-66 Paquin et frère inc.Notice is given that umler Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 12th day of April, 1966, have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Luc Parent.560 Carlyle Ave., Claude Réland.2870 Glencoe Ave., both of Mount Royal.René-C.Alary, 3345 McCarthy, St-Laurent, all three advocates, and Berthe Lafon-taine, secretary, fille majeure.1056 St.Joseph Blvd.Fast.Montreal, for the following purposes: To carry on business as bakers, umler the name of \"Puqiiin et frère inc.\", with a total capital stock of 850.000.divided into 300 common shares of a nominal value of $100 each and 200 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at St-Chry-¦ostome, judicial district of Reauharnois.Raymond Douvillk, Assistant Secretari/ of the Province.15440 1262-66 Pearson et fils ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 26th day of April, 1966, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Emile Pearson, merchant, Roger Pearson, miner, and Huguette Tremblay, housewife, wife contractually separate as to property of the said Roger Pearson, all three of Chibougamau, for the following purposes: 3186 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 11 juin 1906, 98' année, n° 23 Faire affaires comme marchand général, sous le nom de « Pearson et fils ltée », avec un capital total de $40,000.divisé en 3,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacun!1.Ix* siège social de la compagnie est à Chibou-gamau, district judiciaire d'Ahitihi.Le Sous-sccrftaire de la province, Raymond Douvillk.1Ô440-o 1745-00 To carry on business as general merchant, umler the name of \"Pearson et fils ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 8,000 common shares of a nominal value of $10 each and 1,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Chibou-gamau.judicial district of Abitibi.Raymond Dolvii.uk.Assistant Secretary of the Province.15440 1745-66 J.B.Pelletier ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé des lettres patentes, en date du 27e jour d'avril 1900, constituant en corporation: Jean-Baptiste Pelletier, marchand de fourrure, Irène Robitaille, ménagère, épouse dudit Jean-Baptiste Pelletier, tous deux de 823, Monseigneur-Grandin, et Jean-Claude Pelletier, tailleur.3257.Val-Ombreuse, tous trois de Ste-Foy, pour les objets suivants: Faire le commerce de fourrures, sous le non de « J.B.Pelletier ltée ».avec un capital total \u2022 le $40.000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 242, rue St-Jcan, QuébeCi district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.15440-o 1753-00 J.B.Pelletier ltée Xotice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of April, 1906, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Baptiste Pelletier, furrier, Irene Robitaille, housewife, wife of the said Jean-Raptiste Pelletier, both of 823 Monseigneur-Grandin.and Jean-Claude Pelletier, tailor.8257 Val-Ombreuse, all three of Ste-Foy.for tlie following purposes: To carry on business dealing in furs, under the name of \"J.B.Pelletier ltée\", with a total capital stock of $40.000, divided into 400 comm.m shares of $100 each.The head office of the company is at 242 St.John St., Quebec, judicial district of Quebec Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.15440 1763-66 Polyclinique médicale populaire Popular Medical Polyclinic Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de mars 1966, constituant en corporation sans capital-actions: André Léveillé, 4792, rue St-Jacqucs ouest, Jean-Paul Menard, 8315, Souligny, tous deux représentants syndicaux, et Dr Benoit Deshaies, médecin, 230, boulevard Gouin ouest, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Établir et diriger une clinique médicale, chirurgicale et bureaux médicaux, sous le nom de « Polyclinique médicale populaire \u2014 Popular Medical Polyclinic ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $5,000,000.Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.15440-O 1355-66 Polyclinique médicale populaire Popular Medical Polyclinic Xotice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of March, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: André Léveillé.4792 St.James St.West, Jean Paul Menard, 8315 Souligny, both union representatives, and Dr.Benoit Deshaies, physician.230 Gouin Blvd.West, all three of Montreal, for the following purposes: To establish and direct a medical and surgical clinic and medical offices, under the name of \"Polyclinique médicale populaire \u2014 Popular Medical Polyclinic\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $5,000,000.The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Doi villk.Assistant Secretary of the Province.15440 1355-00 Poulet Doré inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour d'avril I960), constituant en corporation: Jacques Lachaine, épicier, Charlemagne Lachaine, et J.-Pros|H*r Côté, ces deux derniers commerçants, tous trois de Lac-Carré, pour les objets suivants: Exploiter des rôtisseries, sous le nom de « Poulet Doré inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 360 actions ordinaires de $100 chacune et en 40 actions privilégiées «le $100 chacune.Poulet Doré inc.Xotice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, liearing «laie the 26th day of April, 1966, have l>ecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacques Lachaine.grocer, Charlemagne Lachaine, and J.-Prosper Côté, the latter two merchants, all three of Lac-Carré, for the following purposes: To operate grill-rooms, under the name of \"Poulet Doré inc.\", with a total capital of $40,000, divided into 360 common shares of $100 each and 40 prcferrctl shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June II, 1906, Val.98, No.23 3187 I c liège social de la compagnie est à Lac-Carre, district judiciaire de Terrebonne.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440-0 1704-00 The head office of the company is at Lac-Carré, judicial district of Terrebonne.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.15440 1704-00 Le Restaurant Au Vieux Rouet inc.le Restaurant Au Vieux Rouet inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé des lettres patentee, en «late du 27e jour d'avril 1066, constituant ett corporation: André Guindon, restaurateur, Lucette Labelle, ménagère, épouse -parce de biens dudit André (iuindon, et Paul (îuindon, contremaître) tous trois de Bte-Agathe- des-Mottts, pour les objets suivants: Paire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Le Restaurant Au Vieux Rouet inc.», avec un capital total de S40,000, divisé en 3.000 act ions ordinaires de 010 chucune et en 40 actions privilégiées de W00 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Stc- Vgathe-des-Monts, district judiciaire de Terre- tanne.I.e Sous-sccrétairc de la province.Raymond Douvillk.15440-0 1551-00 Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 27th day of April.1066, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: André (Juindon.restaurateur, Lucette Labelle, housewife, wife separate us to property of said André Guindon, ami Paul (iuindon, foreman, all three of Stc-Agathe-des-Monts, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Le Restaurant Au Vieux Rouet inc.\".with a total capital stock of 840.000.divided into 3,000 common shares of 810 each ami 10 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Ste- Agathe-des-Monts, judicial district of Terrebonne.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.15440 1551-0») Romin construction inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la l.i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour d'avril 1000), constituant en corporation: Guy Arsenault, avocat, 82, rue Elgin, Monique Jacques, 231, Duffe-rin, et Jocelyne Lacoste, 113, Clarence, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, tous trois de Grandy, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Romin construction inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur nominale de 8100 chacune et en 2.000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 473, rue St-Charles sud, Granby, district judiciaire de Bedford.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.I5440-o 1747-00 Romin construction inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, l>earing date the 22nd day of April, 1906, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Guy Arsenault, lawyer, 82 Elgin Street, Monique Jacques, 231 Dufferin, and Jocelyne Lacoste, 113 Clarence, the latter two secretaries, filles majeures, all three of Granby, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Romin construction inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of a nominale value of $100 each and into 2,000 preferred shares of a nominal value of S10 each.The head office of the company is at 473 St-Charles Street, South, Granby, judicial district of Bedford.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440 1747-66 Sassoon Fasteners & Supplies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour d'avril 1966, constituant en corporation : Jack Lighstonc, avocat, 2176, chemin Fulton, Mont Royal, Jacob L.Rothman, avocat, 7920, chemin Kingslcy, Côte-St-Luc, et Aimé Duranleau, huissier, 183, est, rue Ste-Catherine, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'attaches de textile, fermoir éclair, agrafes, produits d'élastique, fil à coudre et fournitures en textile de toutes sortes, sous le nom de « Sassoon Fasteners & Supplies Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 1,000 actions privilégiées catégorie « A » de $10 chacune et 200 actions privilégiées catégorie « B » de $100 chacune.Sassoon Fasteners & Supplies Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of April, 1966, have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jack Lightstone, advocate, 2176 Fulton Road, Mount Royal, Jacob L.Rothman, advocate, 7920 Kingsley Road, Côte-St-Luc, and Aimé Duranleau, bailiff, 183 St.Catherine East, Montreal, for the following purposes! To deal in textile fasteners, zippers, clips, elastic products, sewing yarns and textiles supplies of ail kinds, under the name of \"Sassoon Fasteners & Supplies Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each, 1,000 class \"A\" preferred shares of $10 each and 200 class \"B\" preferred shares of $100 each. 3188 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.11 juin 1066, 08' année, n\" 28 Le siège social de la compagnie est 55, ouest, avenue Mont Royal» Montréal, district judiciaire de Montréal.L$ Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.15440 1720-66 Jean Séguin & associés inc.Jean Séguin & Asociales Inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de mai 1066, constituant en corporation: Guy Marin, administrateur, 10050, Weverley, Montréal.Jean Séguin, 5570.Des Plaines, (cité Jardin) Montréal, et Paid Séguin, 8370, George, LaSalle, ces deux derniers puolicistes, pour les objets suivants: Exploiter une agence de publicité, sous le nom de « Jean Séguin & associés inc.\u2014 Jean Séguin & Associates Inc.», avec un capital total de §40.000, divisé en 40.000 actions ordinaires de Si chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.l.c Sous-sccrétairc de la province, Raymond Douvillk.15440-o 1579-66 The head office of the company is at 55 Mount Royal Avenue West, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440-o 1720.06 Jean Séguin & associés inc.Jean Séguin & Associates Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 2nd day of May, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Guy Marin, udininistruotr.10059 Waverlcy, Montreal, Jean Séguin.5570 Dee Plaines, (cité Jardin) Montreal, and Paul Séguin.8370 George, LaSalle, the latter two publicists, for the following purposes: To operate a publicity agency, under the name of \"Jean Séguin & associés inc.Jean Séguin & Associates Inc.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dor villi:.Assistant Secretari/ of the Province.15440 1570-',, Société de gestion des Bois-Francs inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé îles lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1966, constituant en cor|Miration: Jcan-Puul Mailhot, gérant.Orner Vachon, conseiller en application domiciliaire, tous deux d'Arthabaska, et Itolwrt Pro-vencher, entrepreneur.Yietoriaville.pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction et de placement, sous le nom île « Société de gestion des Rois-Francs inc.», avec un capital total de $110,000.divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune.1.000 actions privilégiées classe « A » de 850 chacune et en 5,000 actions privilégiées classe « B » de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Victoria-ville, district judiciaire d'Arthabaska.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15140-o 1806-66 Société de gestion des Bois-Francs inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 29th day of April, 1966, have l>ecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Paul Mailhot.manager, Omcr Vachon, counsellor in household application, both of Arthabaska.and Robert Proveiielicr.contractor, Yietoriaville, for the following purposes : To carry on business as a real estate, construction and investment company, under the name of \"Société de gestion des Bois-Francs inc.\", with a total capital stock of $110.001».divided into 1.000 common shares of $10 each.1.000 preferred class \"A\" shares of $50 each and into 5.000 preferred class \"B\" shares of $10 eaeh- The head office of the company is at Victoria, ville, judicial district of Arthabaska.Raymond Douvillk.Assistant Secretari/ of the Province.15440 1806-66 Trapper Quebec Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 14c jour d'avril 1966, constituant en corporation: Robert S.Murray, vendeur, Lise Brien, secrétaire, célibataire, 118, 5e avenue, et W.Warren Lynch, avocat, tous trois de Sherbrooke, pour les objets suivants: Exercer un commerce général d'imprimerie, sous le nom de « Trapper Quebec Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «l'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.15440 1527-66 Trapper Quebec Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of April, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Robert S.Murray, salesman, Lise Brien, secretary, spinster, 118, 5th Avenue, and W.Warren Lynch, advocate, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on a general printing business, under the name of \"Trapper Quebec Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 com mon shares of the par value of $10 each aud 300 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company is at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.15440-o 1527-60 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, 1966, Vol.98, No.23 3189 Turgeon & Thivicrge, inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-ajouverneur de la province a accordé des lettres patentée, en date du 21e jour d'avril 1066, constituant eu corporation: Benoit Turgeon, courtier en assurance, Thérèse I^essard, ménagère, épouse séparée de biens dudit Benoit Turgeon, tous deux de 104, 2e rue, Beauceville-est, et liosc-A.Thivicrge, courtier en assurance, fille majeure, 360, 2e avenue, St-Georges, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers et agents en assurance, sous le nom de « Turgeon & Thivicrge, inc., avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.be siège social de la compagnie est à St-( rcorges, district judiciaire de Beauce.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440-0 1388-66 Yip Leasing Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé des lettres patentes, en date du 29e jour de mars 1066, constituant en corporation: Conrad Shatner, avocat, 1275.Pulton, Montréal.Jo Ann Israel, secrétaire, célibataire, 3606, The Boulevard.Westmount.et Marjorie Bailey, secrétaire, épouse séparée de biens «le Richard Frederick Hyatt Green, 143, Richelieu.St.lean, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et de placements, sous le nom de « Yip Leasing Limited .avec un capital total de $40,000, divisé en 40.000 actions ordinaires de $1 chacune.siège social de la compagnie est 737A.14c avenue.Lachine, «listrict judiciaire de Montréal.I.e Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.15440 1345-66 Volta inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la lx)i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé des lettres patentes, en date du 26e jour d'avril 1066, constituant en corporation: Jacques Marquis, 1305, Pelletier.Sillery.André Marceau.1529.Iioulevard de l'Entente, Québec, et Marc Jessop, 2748, boulevard Liégeois, Stc-Foy, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'éditeurs, imprimeurs, graveurs, relieurs et autres commerces semblables, sous le nom de « Volta inc.», avec un capital total de 810.00).divisé en 40.000 actions ordinaires «le 81 chacune.Le siège social de la compagnie est 130)5.de l.ongueuil, Québec, district judiciaire de Québec.Le Sous-secretaire de la province.Raymond Douvillk.10440-0 1770-00 Wybor Limited Wybor limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour d'avril 1966, constituant en corporation: Adam Wygnanski, chi- Turgeon & Thivicrge, inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 21st day of April, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Benoit Turgeon, insurance broker, Thérèse Lessard, housewife, wife separate as to property of the said Benoit Turgeon, both of 104.2nd St., Beauceville-East, and Rose-A.Thivierge, insurance broker, fille majeure, 360.2nd Ave., St-Georges, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers and agents, under the name of \"Turgeon & Thivicrge, inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at St-(icorges, judicial district of Beauce.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440 1388-06 Yip Leasing Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 201 h day of March.I960), have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province.incorporating: Conrad Shatner.advocate, 1275 Fulton, Montreal.Jo Ann Israel, secretary, spinster, 3606 The Boulevard, Westmount.and Marjorie Bailey, secretary, wife separate as to property of Richard Frederick Hyatt Green.143 Richelieu, St.Johns, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of \"Yip Leasing Limited\", with a total capita! stock of 810.000.divided into 40,000 common shares of 81 each.The head office of the company is at 737A.14th Avenue, Lachine.judicial district of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.151I0-o 1345-66 Yolta inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of April.1066, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacques Marquis, 1305Pelletier, Sillery.André Marceau, 1529 de l'Entente Boulevard, Quebec, and Marc Jessop, 2748 Liégeois Boulevard, Stc-Foy.all three lawyers, for the following purposes: To carry on business us editors, printers, engravers, bookbinders and other similar businesses, under the name of \"Volta inc.\", with a total capital stock of 840.000.divided into 40,000 common shares of 81 each.The head office of the company is at 1305 de Longueuil, Quebec, judicial district of Quebec.Raymond Douvillk.Assistant Secretari/ of the Province.15410 1770-00 Wyhor Limited Wybor limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of April, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor|x>-rating: Adam Wygnanski, chemist, Jadwiga 3100 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Il juin 1906, 98' année, n° 23 inistc, Jadwiga Katz, bibliothécaire, épouse séparée de biens dudit Adam Wygnanski, tous deux de 3833, avenue Oxford, Montréal, Joseph Bo-renstein, gérant, et Lea Tepicht, ménagère, épouse commune en biens dudit Joseph Borens-tein, ces deux derniers de 5750, avenue McMur-ray, Côte-St-Luc, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'électriciens, sous le nom de « Wylwr Limited \u2014 Wylx>r limitée », avec un capital total de $-10,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 cliacune.Le siège social de la compagnie est 2109, avenue de LaSalle, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-sccrétairc de la province, Raymond Douvillk.15440 1743-00 Katz, librarian, wife separate as to property of the said Adam Wygnanski, both of 3833 Oxford Avenue, Montreal, Joseph Rorenstein, manager, and Lea Tepicht, housewife, wife common as to property of the said Joseph Rorenstein, the lut ter two of 5750 McMurray Avenue, C5te-St-I,ue, for the following purposes: To do business as electricians, under the name of « Wylwr Limited \u2014 Wybor limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into lO.ilOO common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 2109 de LaSalle Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretari/ of the Province.15440-o 171; (Hi Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Aluminum Packaging Limited I .es produits d'emballage d'aluminium limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 26e jour d'avril 1966, à la compagnie « Aluminum Packaging Limited », constituée par lettres patentes en date du 20e jour d'avril 1953, changeant son nom en celui de » Aluminum Packaging Limited \u2014 Les produits d'emballage d'aluminium limitée ».Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440 6772-53 \u20141320/33 Amicale Cauvin de Hull inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province, des lettres patentes supplémentaires en date du 20e jour d'avril 1060, à « La Société des anciens élèves des P.E.C.inc.(Section St-Rédenipteur de Hull) », constituée en corporation par lettres patentes du 15 mai 1957.1° changeant son nom en celui de « Amicale Cauvin de Hull inc.»; 2° modifiant ses pouvoirs.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440-o 11390-57 \u2014 1319/108 Bourassa, Gagnon et associés, inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour d'avril 1966, à la compagnie « Bourassa, Gagnon et associés, inc.», 1° modifiant ses pouvoirs; 2° convertissant ses 3,000 actions ordinaires non émises d'une valeur nominale de $10 chacune en 3,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune; 2° augmentant son capital de $40,000 à $80,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 4,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.15440-o 2869-65\u20141320/28 Aluminum Packaging Limited Les produits d'emballage d'aluminium limitée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, l>earing date the 26th day of April, 1966, have l>een issued by the Lieutenant-Governor of Ilu-Province to \"Aluminum Packaging Limited\"', incorporated by letters patent dated the 20th day of April, 1953, changing its name to that of \"Aluminum Packaging Limited\u2014Les produits d'emballage d'aluminium limitée\".Raymond Douvillk, Assistant Secretari/ of the Province.15440-o 6772-53 \u2014 1820/33 Amicale Cauvin de Hull inc.Notice is hereby given that under the Com* panies Act, the Lieutenant-Governor of the Province lias been pleased to grant supplementary letters patent dated the 20th day of April, 1066, to \"La Société des anciens élèves des F.E.C.inc.(Section St-Rédempteur de Hull)\", incorporated by letters patent dated the 15th day of May, 1957, 1.changing its name into that of \"Amicale Cauvin de Hull inc.\"; 2.amending ils powers.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440 11390-57\u2014 1319/10^ Bourassa, Gagnon et associés, inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, hearing date the 29th day of April, 1966, have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Bourassa, Gagnon et associés, inc.\", 1.amending its powers; 2.converting its 3,000 unissued common shares of a nominal value of $10 each into 3,000 preferred shares of a nominal value of $10 each; 3.increasing its capital stock from $40,000 to $80,000, the additional share capital l>eing divided into 4,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.15440 2869-65 \u20141320/28 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, 1066, Vol.98, No.2.1 C.T.K.distribution inc.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 2e jour de mai 1066.à la compagnie « C.T.R.distribution Inc.étendant ses pouvoirs.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.lâiin-o 2147-00 \u20141320/40 Camp Bnai Brith Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première pailic de la i/ii des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 27e jour d'avril 1900, à la compagnie < Camp Ruai Rrith Inc.augmentant le montant des biens immo-liiliers que la corporation peut posséder ou détc-iii de 860,000 à $1.250,000.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.15440 1060-30- 1319/135 I .een issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Sogena inc.\", increasing its capital stock from $2,000,000 to $4,000,000, the additional share capital being divided into 20,000 preferred shares of a nominal value of $100 each.Raymond Douvillk, Assistant Secretari/ of the Province.15440 10245-02 \u2014 1320/15 Order in Couneil Arrêté en conseil Chambre du Conseil Kxécutif Numéro 940 Québec, le 18 mai 1066.Présent: I^c Lieutenant-gouverneur en conseil.concernant un règlement au sujet de la nomination des commissaires à l'assenneutation |k>ur le Québec.Attkndu qu'à compter du 1er septembre 1966, les personnes autorisées à faire prêter le serinent seront les commissaires à l'assenncntation nommés par commission sous le sceau du ministre de la justice, conformément aux dispositions des articles 223 et suivants de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.Q., 1964, chapitre 20), tel qu'amendée par la loi 13-14 Elizabeth II, chapitre 17; Attkndu quk, conformément aux dispositions de l'article 225 de la même loi, ces commissions ne sont délivrées qu'aux conditions fixées par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil publié dans la Gazette officielle de Québec; Attkndu qu'il y a lieu de passer un tel règlement.Il est ordonné en conséquence, sur la proposition du Ministre de la justice: Quk, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des tribunaux judiciaires, (S.R.Q., 1964, chapitre 20), tel qu'amendée par la loi 13-14 Elizabeth II, chapitre 17, de règlement suivant soit édicté: Order in Council Executive Couneil Chamber Number 940 Québec, May 18, 1066.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Conckrning a regulation relative to the appointment of commissioners for Oaths for Quebec.Whereas from and after September 1, 1966, the persons authorized to administer oaths will l>e the commissioners for Oaths appointed by commission under the seal of the Minister of Justice, pursuant to the provisions of sections 223 and those following of the Courts of Justice Act (R.S.Q., 1964, chapter 20), as amended by Act 13-14 Elizabeth II, chapter 17; Whereas, pursuant to the provisions of section 225 of the same Act, the commissions shall be issued only under the conditions fixed by regulation of the Lieutenant-Governor in Council and published in the Quebec Official Gazette; Whereas it is expedient to pass such a regulation.It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Justice: That, pursuant to the provisions of section 225 of the Courts of Justice Act, (R.S.Q., 1964, chapter 20), as amended by Act 13-14 Elizabeth II, chapter 17, the following regulation be enacted: 3194 FAZKTTK OFFICIELLE DE QUÉBEC, 11 juin 1966, 98' année, n° 28 Règlement, concernant les commissaires à l'asscr- mentation pour le Quëliec.lies commissions prévues aux articles 223 et 224 de la IiOi des tribunaux judiciaires, (S.R.Q., 1004.cliapitre 20), -tel qu'amendée par la loi 13-14 Kli/abelh II, chupitre 17, sont délivrées pour une période de cinq années moyennant le paiement «l'un honoraire de dix ($10.00) dollars.Ces commissions pourront être renouvelées «le cinq ans en cinq ans moyennant le paiement d'un honoraire de cinq dollars ($5.00) pour chaque période ailditionnelle.Les personnes qui, le 31 août 1900, étaient, commissaires de la (.'our Supérieure et dont la nomination à cette fonction deviendra inopérante, le 1er septembre 1900, date de la mise en vigueur du nouveau Code de proctMure civile, (13-14 Elisabeth II, chapitre 80), pourront être nommées COnunissairei à l'asscrmcutation moyennant un honoraire «le cinq dollars ($5.00) pour l'obtention de la commission et un honoraire additionnel de cinq dollars ($5.00) pour chaque autre pério«lc de c iii'i ans.Ce règlement, après publication «lans la Gazette officielle de Québec, entrera en vigueur le 1er septembre 1900.Copie conforme.Le Greffier du Conseil Exécutif, 15488-o Jacques Pkémont.Regulation concerning commissioners for oaths for the district of Quebec.The commissions contemplated in section- 223 and 224 of the Courts of Justice Act (R.S.(|, 1964, chapter 20), as amended by Act 15-14 Elizabeth II, cliapter 17, are issued for a period of five years and on payment of a ten delist ($10.00) fee.These commissions may l>c renewed ever) five years on payment of a five dollar ($5.01' fee for each additional period.The persons who, on August 31, 1966, wen commissioners of the Superior Court an«l w hose appointment to this office will become invalid on September 1, 1966, date of the coining into force of the new Code of Civil Procedure, (13-14 Elizabeth II, chapter 80), may be appointed commissioners for Oaths on payment of a live dollar ($5.00) fee to obtain the commission ami an additional fee of five dollars ($5.00) for each other five-year period.This regulation, after publication in the Quebec Official Gazette, will enter into force on September 1, 1966.True copy.Jacques Prémont, 15488 Clerk of the Executive Council.Ministère du Travail Department of Labour Avis de prélèvement L'honorable Carrier Fortin, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité conjoint de l'Imlustrie des Vêtements d'hommes et de garçons «lans là province de Québec, établi en exécution du décret numéro 711 du 30 avril 1963, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 995 «lu 31 mai 1966, section « F », le tout, «l'acoonl avec les dispositions «le la Loi des décrets «le convention collective (Statuts refondus de Québec 1964, chapitre 143), à prélever des cotisations des employeurs professionnels et «les salariés assujettis audit décret, suivant les conditions ci-après décrites: Notice of levy Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q.1964.chapter 143), the Honourable Carrier Fortin, Minister «>f Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Men's and Roys' Clothing Industry for the Province of Quebec (established in pursuance of decree number 711 of April 30, 1903) has been authorized to levy «lues on the professional employers and employees subject to the said decree, acconling to conditions mentioned below.A by-law, approved by Order in Council number 995 of May 31.1966.section \"K\".authorizes such levy.1.Cotisation La période «le cotisation s'étend du 1er juillet 1966 au 1er juillet 1967; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 711 et amendements doivent verser au Comité conjoint une .somme équivalente à }i «le 1% «le leur liste «le paye pour les les salariés assujettis audit décret.b) Les salariés régis par ledit décret numéro 711 et amendements doivent verser au Comité conjoint une somme équivalente à }4 «le 1% «le leur rémunération.1.Dues The contribution period extends from July 1.1966, to July 1, 1967.It is carried out as folio* *: (a) Professional employers governed by said decree number 711 ami amendments shall pay the Parity Committee an amount equivalent to \\i of 1% of their payroll for the employées subject to the said decree.(b) Employees governed by said decree number 711 and amendments, shall turn over to the Parity Committee an amount equivalent to xi of 1% of their wages.2.Mode de perception En vue «le faciliter la perception de ces cotisations, le Comité conjoint met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité conjoint à chaque mois.2.Collection method To facilitate the collection of such dues, tile Parity Committee supplies professional employers with report forms on which all the information requested by the said Parity Committee must l>e given.must be given.Every month, the professional emploer must complete, sing and forward bin report to the Parity Committee. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, I960, Vol.98, No.28 3195 L'employeur professionnel doit percevoir) à la tin .U- chaque semaine, au nom of 1% of their fixed salaries, commissions, bonuses and allowances.2.Collection method To facilitate the collection of such dues, the Commission supplies professional employers with report forms which contain the following information: hours worked; wages paid, including the proportion of commissions earned; money collected during the week and amounts turned over to the Joint Commission.The professional employer must see that these reports he completed and forwarded to the Joint Commission, each month.At the end of each week, by means of a checkoff the professional employer must collect the sums due the Joint Commission.He must forward them himself to the Joint Commission together with his own dues.The professional employer's report whù h accompanies the dues, must be signed and forwarded to the Joint Commission within the ten (10) days following the expiry date of the jMjriod for which it is required The Commission has the authority to requets an attestation of the said report whenever it shall deem it advisable.Every month, artisans must also forward the «lues payable to the said Commission on or before the 10th of the month following the expiry dale of the period for which they are required.The levy imposed by this by-law is payable monthly by the professional employer, the employer, the artisan and the employee, without formal notice taforehand and within the ime limit mentioned above. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, 1966, Vol.98, No.23 3199 3.Bap port financier D'accord avec les dispositions de la Loi des ,|, rets de Convention Collective, la Commission Conjointe doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 piiii, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.( 'i-annexé, un état des recettes et des dé!>oursés prévus de la Commission Conjointe des Coiffeurs pour Dames de Montréal, pour la période comprise entre le 2 juillet 1060 et le 2 juillet 1967.Commission conjoint» des Coiffeurs pour dames de Montréal État des recettes et des déboursés pour la période comprise entre le 2 juillet 1966 et le 2 juillet 1967.Recette»'.(otisations patronales.S 46,324.00 ( otisations ouvrières.46,324.00 ( otisations artisanales.18,812.00 I Vitalités et amendes.762.00 I )i immages : intérêts liquidés.5,000.00 Honoraires d'examen.8,100.00 He venus de loyer.2,000.00 Iutérêts de banque.3,000.00 Impôt fédéral.5,500.00 Impôt provincial.3,700.00 Assurance-chômage.400.00 Rentes du Québec.600.00 $140,522.00 Déboursé.*: Salaire du secrétaire.$ 8,320.00 Salaire du personnel.46,660.00 Salaires des inspecteurs.23,400.00 Frais d'inspection.7,220.00 Honoraires: Bureau d'examinateurs 0,300.00 Frais : Bureau d'examinateurs.2,500.00 Lover et taxes.2,400.00 Eclairage, cliauffage, entretien.4,000.00 Frais judiciaires,.7,000.00 Frais de vérification.1,000.00 Impression, papeterie, acc.de bureau.7,500.00 Poste, téléphone, télégramme.5,000.00 AI>oimemcnt et publicité.700.00 Jetons de présence (membres du Comité).1,200.00 Frais de déplacements (membres du Comité).3,500.00 Frais de délégation.1,000.00 Frais d'affiliation.700.00 Assurance-chômage.800.00 Assurance-groupe.550.00 Assurance caution.10.00 Assurances générales.102.00 Impôt fédéral.5,500.00 I mpôt provincial.3,700.00 Hen tes du Québec.1,200.00 $140,522.00 Le sous-ministre du Travail, Gerard Tremblay.-Ministère du Travail, Québec, le 11 juin 1966.15449-o Avis de prélève nient L'honorable Carrier Fortin, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité 3.Financial report In compliance with the provisions of the Collective Agreement Decrees Act, the Joint Commission must submit a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour on the following set dates: March 31, June 30.September 30 and December 31 of each year.A statement of estimated receipts and disbursements of the Joint Commission of the Ladies-Ilairdrcssing Trade of Mont nul for the July 2.1906 to July 2, 1967 period is given below.Joint Commission of tiif.Ladif.s Haihdrkssino Trade of Montreal Statement of receipts and disbursements for the July 2, 196»i to July 2.1907 period.Receipts: Employers' dues.§ 40,324.00 Employees' dues.40,324.00 Artisans'dues.18.812.00 Penalties and fines.762.00 Damages: paid-off interest.5.000.00 Examination fees.8.100.00 Rent income.2.000.00 Bank interest.3,000.00 Federal tax.5,500.00 Provincial tax.3,700.00 Unemployment Insurance.400.00 Québec Pension Plan.600.00 $140,522.00 Disbursements: Secretary's salarv.$ 8,320,00 Staff's salary.40.000.00 inspectors' salaries.23,400.00 Inspect ion expenses.7,220 00 Fees: Board of Examiners.6,300.00 Expenses: Board of Examiners.2,500.00 Rent and taxes.2,400.00 Lights, heat, maintenance.4,000.00 Legal fees.7,000.00 Auditor's fees.1,000.00 Printing, stationery, office equipment.7,500.00 Postage, telephone, telegrams.5.000.00 Subscription and advertising.700.00 Attendance tokens (Committee members).1,200.00 Travelling expenses (Committee members).3,500.00 1 ^legation expenses.1,000 00 Affiliation fees.700.00 Unemployment Insurance.800.00 Group insurance.550.00 Fidelity bond.10.00 (ieneral insurance.102.00 Federal tax.5,500.00 Provincial tax.3,700.00 Quéliec Pension Plan.1,200 00 $140.522.00 Gérard Tremblay, Deputy MiniAcr of Labour.Department of Labour.Quebec.June 11.1960.\u2022 16449-0 Notice of levy Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (Revised Statutes of 3200 GAZETTE OFFICIELLE DÉ QUÉBEC, 11 juin I960, 98' année, n° U conjoint de l'Industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec, établi en exécution du décret numéro 385 du 19 avril 1956 et amendements, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 995 du 31 mai 1966, section «G», le tout d'accord avec les dispositions de la Loi des décrets «le convention collective (Statuts refondus de Québec 1964, chapitre 143), ù prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret, suivant les conditions ci-après décrites: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 30 juin 1966 au 30 juin 1967; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis pur ledit décret numéro 385 et amendements doivent verser au ( 'oinité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% des salaires fixes et des pourcentages payés à leurs salariés.b) Les salariés régis par ledit décret numéro 385 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 1 ¦> de 1% de leur rémunération.2.Moite de perception En vue «le faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition «les employeurs professionnels des formules «le rapport sur lesquelles doivent être indiqués les heures de travail, le montant perru pendant la semaine et les sommes versées au Comité paritaire.Les employeurs professionnels doivent voir à ce que les rapports soient remplis et retournés au Comité paritaire tous les mois.Les employeurs professionnels doivent percevoir, ù la fin «le chaque semaine, à même les salaires de leurs salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire.Le rapport de l'employeur professionnel «loit être signé avant d'être adressé au Comité paritaire.Ledit Comité paritaire a le droit d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le rapport accompagné des cotisations «loit être adressé au Comité paritaire le ou avant le mercredi suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible.Sur réception dudit rapport, le Comité paritaire en fera la vérification et débitera ou cré«litera le compte de la partie intéressée selon que les montants transmis seront plus ou moins élevés que le montant «lû.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi des décrets de Convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.Ci-annexé, un état des recettes et «les déboursés prévus «lu Comité conjoint de l'Industrie des chapeaux en toile et «les casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province «le Québec, pour la période comprise entre le 30 juin 1966 et le 30 juin 1967.Quebec 1964, chapter 143), the Honourable Carrier Fortin, Minister fo Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Men anil Boys' Hat ami Cap Industry for the Province of Quél>ec (established in pursuance of decree number 385 of April 19, 1950 and amendment s) has been authorized to levy dues on the professional employers ami employees subject to the said decree, according to the conditions outlined below, A by-law, approved by Order in Council number 995 of May 31, 1900), sect ion \"C\".authorizes such levy.1.Dues The contribution period extends from June 30, 1966 to June 30.1907.It is carried out as follows: (a) Professional employers governed by said decree number 385 and amendment* shall pay the Parity Committee an amount equivalent I\" Cj of 1% of the fixed salaries and percentages paid to their employees.(b) Employees governed by said decree nuni her 385 and amendments shall turn over to the Parity Committee an amount equivalent to 1 \u2022_» °f 1% of their wages.2.Collection method To facilitate the collection of such «lues, the Parity Committee supplies professional employers with report forms indicating the work hours, amount collected during the Week and the amounts turned over to the Parity Committee.Professional employers must see that these reports be completed and forwarded monthly to the Parity Committee At the end of each week, professional employers must deduct the amounts owing the Parity Committee from the wages of their employees.The professional employer's report must be signed before being forwarded to the Parity Committee.The said Committee has the authority to request an attestation of the said report whenever it shall deem it advisbale.The re|>ort together with the dues must be forwarded to the Parity Committee on or before Wednesday following the expiry «late of the period for which it is required.After receiving the said report, the Parity Committee will check same and debit or credit the interested party's account if the amounts forwarded arc more or less than the amount due 3.Financial report In compliance with the provisions of the Collective Agreement Decrees Act, the Parity Committee must submit a quarterly financial report to the Minister of Labour on the following set dates: March 31, June 30, September 30 and December 31 of each year.A statement of estimatetl receipts and disbursements of the Joint Committee of the Men am! Boys' Hat and Cap Industry for the Province of Quebec, for the June 30, 1966 to June 30, 1967 period is given below. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, 1966, Vol.98, No.23 3201 Lb Comité Conjoint dk l'Industrie deb cli ape aux en toile et deh casquettes pour iiommeh, oahçonb et enfants dans la province de québec État de 1% du salaire du salarié le moins rémunéré, soit sur une base de $20.00 par semaine.c) Les salariés régis par lesdits décrets numéros 20, 2141 et leurs amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à i£ «le 1 % de leur rémunération.2.Mode de perception En vue «le faciliter la perception «le ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules sur lesquelles doivent être indiqués tous les rensei- Rent.$1.800.00 Lights, heat,maintenance.600.00 Legal fees.1,800.00 Auditor's fees.400.00 Printing, stationery, office eipiipment 2.000.00 Interest, exchange, agio.50.00 Postage, telephone, telegrams.850.00 Subscription and advertising.100.00 Attendance tokens (Committee members)._.750.00 Travelling expenses (Committee members).2,500.00 Delegation expenses.400.00 Unemployment Insurance 550.00 Group health insuruiice.800.00 ( Seneral insurance.575 00 Fidelity bond.15.00 Federal tax.1,800.00 Provincial tax.1,300.00 Québec Pension Plan.1.000.00 Pension fund.3,200.00 Training courses.2.000.00 $02,020.00 Surplus.$ .500.00 Gkraro tltk.mui.av.Deputy Minister of Labour.Department of Labour.Québec, dune 11.1966.IÔ440-o Notice of levy Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (Revised Statutes of Québec, 1904.chapter 143).the Honourable Carrier Fortin.Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint C«;mmittee of the Retail F«)o«l Trade of Sherbrooke ami vicinity (established in pursuance of decree number 20 of January 5.1955) has been authorised to levy dues on the professional employers, artisans and employees subject to the said decree, according to the conditions mentioned below.A by-law.approve«l by Order in Council number 995 of May 31.1966.section \"E\", authorizes such levy.1.Dues The contribution period extends from July 1.191)6.to July 1.1967.It is carried OUt us follows: (a) Professional employers governed by saitl decrees numbers 20.2141 and amendments shall pay the Parity Committee an amount equivalent to J ¦> of 1% of their payroll for the employees subject to the said decrees.(//) Artisans governed by said decrees numbers 20.2141 and ametulments shall turn over to the Parity Committee an amount equivalent to } \u2022> of 1% of the wages earned by the lowest-paid employee, i.e., a $20.00 a week basis.(c) Employées governed by said decrees numbers 20.2141 ami amendments shall turn over the Parity Committee an amount equivalent to 1 j of \\% of their wages.2.Collection method To facilitate the collection «>f such «lues, the Parity Committee supplies professional employers with report forms on which ull the information requested by the said Parity Committee 3204 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 11 juin 19(H).98' année, n\" 28 giumionts exigés par ledit Comité paritaire.I/employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à la fin de chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 10 du mois suivant la date d'expiration do la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et de celle de ses salariés.\\/t Comité a le pouvoir «l'exiger l'assc r) ne n ta t ion dudit rapport chaque fois qu'A le juge à propos.Le prélèvement imposé pair le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au prélablc.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.8.Rapport financier Conformément aux dispositions de la Loi des décrets de Convention Collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.Ci-annexé.un état «les recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire de l'Alimentation au détail de Sherbrooke et région pour la période comprise entre le 1er juillet 1006 et le 1er juillet 1967.Comité paritaire de l'Alimentation au détail de sherbrooke et région\" 4C0, Alexandre, apt.3.Sherbrooke État «les recettes et «les déboursés prévus du Comité paritaire précité, chargé de l'administration «les décrets numéros 20, et 2141 pour la période du 1er juillet 1966au 1er juillet 1907.Recettes: ( 'otisations patronales.$ 7.500.00 ( 'otisations ouvrières.7,500.00 Cotisations artisanalcs.650.00 Pénalités et amende.50.00 Intérêts de banque.200.00 Impôt fédéral.500.00 Impôt provincial.300.00 Rentes du Québec.79.20 $16,779.20 Déboursés: Salaire «lu secrétaire.$ 5,200.00 Salaire des inspecteurs.3,000.00 Frais «l'inspection.1,000.00 Loyer et taxes.642.00 Éclairage, chauffage, entretien.50.00 Frais judiciaires.100.C0 Frais de vérification.140.00 Impression, papeterie, accessoires «le bureau.4CO.0O Posté, téléphone, télégramme.300.00 must be given.Every month, the professional employer shall complete, sign ami forward his report to the Parity Committee.At the end of each week ami on the Committee's Iwhalf.the professional employer shall collect this levy by means of a ekeck-off.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity Committee on or lieforc the 10th of the month following the expiry «late of the period for which it is required, The professional employer's «lues together with those of his employees shall accompany the said report.The Committee has the authority to request an attestation of the said report when, «¦ver it shall deem it advisable.The levy impose»! by this by-law is payable monthly by the professional employer, the artisan and the employee, without formal notice beforehand.Should a professional employer «>r an artisan refuse to pay his «lues or supply necessary information, he will Ih* given five (5) days notice so that he may fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report In compliance with the provisions »>f tin Collective Agreement Decrees Act.the Parity Committee must submit a quarterly re|M>rt of its financial operations to the Minister of Labour on the following set dates: March 31st.June 30th, September 30th and December 31st of each year.A statement of estimated receipts and disbursements «;f the Joint Committee of the Retail Food Trade of Sherbrooke and vicinity for tin-July 1,1966 to July 1.1967 period is given below.The Joint Committee oe the Retail Foof Trade or Sherbrooke and vicinity Apt.3, 400 Alexandre.Sherbrooke Statement of estimated receipts ami disbursements of the aboveinentioned Parity Committee, entrusted with the administration «>l decrees number 20 and 2141, for the July I.1906 to July 1, 1907 period.Receipts: Employers'dues.$ 7,500.00 Employees' «lues.7,500.()(I Artisans'dues.(550.00 Penalties and fines.50 00 Rank interest.200.00 Federal tax.800.00 Provincial tax.300.00 Québec Pension Plan.79.20 $16.779.20 Disbursements: Secretary's salary.$ 5,200.00 Inspectors' salaries.3,000.00 Inspection expenses.1,000.00 Rent and taxes.642.00 Lights, heat, maintenance.50.00 Legal fees.100.00 Auditor's fees.140.00 Printing, stationery, office equipment 400.00 Postage, telephone, telegrams.300.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, 1900, Vol.98, No.23 3205 Abonnementet publicité.$ 500.00 Jetons f no more than 82.00 for a journeyman (skilled worker) ami Si.00 for an apprentice. 3206 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 11 juin 1966, 98' année, n\" 23 Le Comité paritaire peut reconnaître lu validité des certificats de qualification émis par les autres comités paritaires.À cette fin, les détenteurs de tels certificats doivent les faire vérifier et enregistrer au bureau du Comité paritaire et fournir les deux photos que ce dernier exige.» Le sous-ministre du Travail, CÉHAHi) Tbbmblay.Ministère du Travail, Québec, le 11 juin 1066, 15449-o The Parity Committee may recognize the validity of competency certificates issued by other parity committees.Holders shall have -ueli certificates checked and recorded at the 1' ity Committee's offices and supply the two phi id-graphs requested by the committee.'' ( ¦ i.kaud Tbbmblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Québec, June 11.1900.16410*0 Avis do modification Barbiers, coiffeurs et coiffeuses Région de Vwtoriavule L'honorable Carrier Fortin, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément sus dispositions «le lu Loi «les décrets «le convention collective (S.R.Q.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective «le travail rendue obligatoire par le décret numéro 98 «lu 29 janvier 194S et amendements, relatif aux métiers «le barbier, coiffeur pour hommes et coiffeurs pour dames «les villes «le Yietoriaville, «l'Arthabaska, «le Plessisville «le Princeville cl du village «le Warwu-k, lui ont présenté une reipiête à l'effet «le soumettre à l'appréciation et à lu décision «lu lieutenant-gouverneur en conseil les mo«lifications suivantes audit décret.1° Ix» nouvel article 108 suivant sera ajouté à la Deuxième Partie: « 108.L'employeur «loit ac«'or«ler à son salarié, un congé «le maladie n'excédant pas «hiu/.e (12) jours par année, ni trois (3) jours ouvrables consécutifs par maladie, sans réduction de salaire.» 2° Les paragraphes *o» et «6» de l'article 110 seront remplacés par les suivants: « a) Employés permanents: Les coiffeurs pour hommes permanents détenteurs d'un certificat «le «|Ualification «le classe « 11 >: doivent recevoir une rémunératuin «le cin«tuantc-cin une rémunération de soixante ($60.00) «hdlars par semaine.b) Employés surnuméraires: Un salarié «le classe « B \u2022 ou «le classe « A » embauché de façon temporaire ou comme remplaçant, a droit à un salaire «le douze ($12.00) dollars par jour.3° L'article 112 sera remplacé par le suivant: « 112.Durée du travail: Pour les fins «lu «lécret, lu «lur«;e «lu travail est répartie de la façon «lécrite ci-dessous mais il est |iermis «le terminer le travail pour les personnes «mi sont à l'intérieur du salon lors «le la fermeture, exception faite pour les cas prévus plus bas.sans «\u2022«instituer une dérogation au décret.Notice of amendment Barbcring and llairdrcssiug trades \\ 'ictoriaville region Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q.1964, chapter 143).the Honourable Carrier Fortin, Minister of Labour, hereby gives notice that the contracting parties t the collective labour agreement respi et- itig the Barbcring and Hainlressing trades in the towns of Yietoriaville, Arthabaska.Plessisville.Princeville ami the village of ^Yarwick (made binding by decree number 98 of January 29.1948 and amendments) have petitioned him to submit the following amendments to the said «lecree to the consideration ami decision of the Lieutenant-Governor in Council: 1.A new sect ion 108 will be added to Part Two, as follows: \"Employers shall grant their employees a maximum of twelve days' sick leave with pay per year.No more than three (3) consecutive Working days may be taken per illness.\" 2.Subsections \"«\" ami \"//' of section 110 will lie replaced by the following: \"a) Permanent employees: Permanent men's hairdressers holding a class \"B\" competency certificate shall be pai«l fifty-five dollars ($65.00) a week: holders of a class \"A\" certificate shall tie paid sixty dollars (860,00) a week.b) Occasional employee: Class \"B\" or \"A\" employees, hired on a temporary basis or as substituting employees, shall lie paid twelve dollars ($12.00) a day.\" 3.Section 112 will be superseded by the following; \"112.Hours of work: For the purposes tif tli> decree, hours of work are as scheduled lielow, Nevertheless, it is permissible t«i finish work for customers in the salon at closing time, excepl cases mentioned hereafter, without running conn ter to the «lecree.Coiffeurs pour hommes Zones I et II Ia: lundi: de 8 a.m.a midi.Les mardi, mercredi et jemli: «le 8 a.m.à 0.30 p.m.Le vendredi: de 8 a.m.à 9 p.m.Le samedi: «le 8 a.m.à midi (dernier client à midi), Exceptions: a) Toutefois, dans les villes «le Plessisville, Princeville, Arthabaska, Warwick et un rayon de cinq (5) milles de leurs limites, 'heure de fermeture est fixée à 7.30 p.m.les mardi, mercredi et jeudi.Men's hairdressers Zones I and II Monday: 8:00 a.m.to noon.Tuesday, Wednesday and Thursday: 8:00 a.in to 0:30 p.m.Friday: 8:00 a.m.to 9:00 p.m.Saturday: 8:00 a.m.to noon (last customer al noon).Exceptions: (a) In the towns of Plessisville.Princeville, Arthabaska.Warwick and a 5-mile radius from their limits, closing time is at 7:30 p.m.«in Tuesday, Wednesday and Thursday. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, 1900, Vol.98, No.23 3207 Il n'y u aucun travail le lundi durunt les mois de juillet et août, duns tout le champ (l'application territorial ».1° (.'enumeration des services rendus uu public, apparaissant à l'article 113 sera remplacée par la suivante: il3.Prix minimaux des services: Lei employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés doivent charger au public I.- prix minimaux suivants pour les services ci-dessous mentionnés: Zones I el II: i tupt de cheveux: Pour enfants de moins de 15 uns 10.70 Pour adultes.1 26 I ,iij>e de cheveux en brosse: Pour enfants de moins de 15 ans 0.00 Pour adultes.1 ,50 Coupe de chevaux uu rasoir y compris le shampooing et l'ondulation.3.00 Ondulation.0.75 Barbe.0.75 Shampooing.0.85 Message ù la crème.0.75 Message ù la glaise.1 .00 Message ù l'huile.1 .25 Lotion ou tonique.0.25 Flambage des cheveux.0.25 Aiguisage de rasoir.0.50» 5e L'article 114 sera remplacé par le suivant: « 114.Prorata des apprentis: Dans chaque salon, il ne doit pas y avoir plus de deux (2) apprentis par coiffeur compétent.» 6° L'article 115 sera remplacé par le suivant: « 115.Salaires minimaux: Le salaire régulier |MUir les heures normales est le suivant dans les zones I et II: a) Employés permanents: Les coiffeurs pour dames permanents détenteurs d'un certificat de qualification de classe « B » doivent recevoir une rémunération de quarante-cinq (§45.00) i lollars par semaine et ceux de la classe « A » une rémunération de cinquante (S50.00) dollars par semaine.b) Employés surnuméraires: Un employé de \u2022 lasse « B » ou de classe « A » embauché de façon temporaire ou comme remplaçant, a droit à un stlairc de dix ($10,00) dollars par jour.» 7° L'article 117 sera remplacé par le suivant: « 117.Durée du travail: Pour les fins du décret, la durée du travail est répartie de la façon décrite ci-dessous mais il est permis de terminer U\" travail pour les personnes qui sont à l'intérieur «lu salon lors de la fermeture, exception faite |Kiur les cas prévus plus bas, sans constituer une dérogation au décret.Coiffeurs pour dames Zones I et II I lundi : aucun travail.Les mardi et jeudi: de 9 a.m.à 7 p.m.(dernière cliente terninée 7 p.m.précise).Les mercredi et vendredi: de 9 a.m.à 10 p.m.Le samedi: de 7.30 a.m.à 1 p.m.(dernière cliente terminée à 1 p.m.précise).Les veilles de fêtes chômées: de 7.30 a.m.à 7 p.m.(dernière cliente terminée à 7 p.m.précise).Lorsqu'une fête chômée tombe un mercredi \"u un vendredi, la veille de cette fête: de 7.30 (b) During July ami August, there is no work on Mondays in all the territorial jurisdiction of the decree.\" 4.The services listed in section 113 will be replaced by the following: \"113.Minimum prices of services: Professional employers, employers, artisans und employees shall charge the following minimum prices for the services mentioned hereafter: Zones I and II: Haircut: Children under 15 .80.75 Adults.1.25 Brushcut: Children under 15.0.90 Adults.1.50 Razor cut.including shampoo and setting 3.00 Waving.0.75 Shave.0.75 Shampoo.0.85 ( ' ream massage.0.75 Mud pack.1.00 Oil massage.1.25 (ahion or tonic.0.25 Hair singeing.0.25 Razor st ropping.0.50\" 5.Section 114 will Ik» superseded by the following: \"114.Batio of apprentices: There shall he no more than two (2) apprentices for each qualified hairdresser, in any one salon.\" 0.Section 115 will be replaced by the following: \"115.Minimum wages: The standard wages for standard working hours in zones I ami II arc as follows: (a) Permanent employees: Permanent ladies' hairdressers holding a class \"B\" comjietency certificate shall be paid forty-five dollars ($45.00) a week; holders of a class \"A\" certificate shall be paid fifty dollars ($60.00) a week.(6) Occasional employees: Class \"B\" or \"A\" employees, hired on a temporary basis or us substituting employees, shall l>e paid ten dollars (SI 0.00) a day.\" 7.Section 117 will be superseded by the following: \"117.Hours of work: For the purposes of the decree, hours of work are as scheduled lie low.Nevertheless, it is permissible to finish work for customers in the salon at closing time, except cases mentioned hereafter, without running counter to the decree.Ladies ' ha irdressers Zones I and II Monday: no work.Tuesday and Thursday: 9:00 u.m.to 7:00 p.m.(last customer to l>e finished for 7:00 p.m.sharp.) Wedncsduy and Friday: 9:00 a.m.to 10:00 p.m.Saturday: 7:30 a.m.to 1 :()() p.m.(last customer to Ix* finished for 1:00 p.m.sharp.) Eves of holidays: 7:30 a.m.to 7:00 p.m.(hist customer to l>c finished for 7:00 p.m.sharp).When a holiday falls on u Wednesday or a Friday, the eve of such holiday: from 7:30 a.m 3208 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 11 juin 1900, 98' année, n° 23 a.m.ù 10.30 p.m.(dernière cliente terminée à 10.30 p.m.précise).Du 18 au 31 décembre: de 9 a.m.à 10 p.m.La veille tie Xoël et du premier de l'An: de 7.30 a.m.à 7 p.m.(dernière cliente terminée a 7 p.m.précise).Exception: Dans la zone I, les mercredi et vendredi: de 9 a.m.à 10.30 p.m.(tlernière cliente terminée à 10.30 p.m.précise).» 8° Les nouvelles opérations suivantes seront ajoutées à l'article 122: « Ondulât ton au fer ou au papier.81.00 Épilat ion des sourcils.0.35 Fixatif (laque).0.25» 9° L'article 123 sera remplacé par le suivant: « 123.Prorata des apprentis: Dans chaque salon, il ne doit pas y avoir plus tie deux (2) apprentis pur coiffeur compétent.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date tie sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours ù compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections, en double copie si possible, que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre du Travail, gérahi) Themblav.Ministère du Travail, Québec, le 11 juin 1906.I5449-0 to 10:30 p.m.(last customer to be finished for 10:30 p.m.sharp).December 18th through 31st: 9:00 a.m.t.10:00 p.m.Christmas ami New Year's Eves: 7.30 a.m.to 7:00 p.m.(last customer to lie finished for 7:00 p.m.sharp).Exception: In zone I, on Wednesday and iri.day: 9:00 a.m.to 10:30 p.m.(last customer I \u2022 be finished for 10:30 p.m.sharp).\" 8.The following new services will be added hi section 122: \"Paper or iron wage.81 00 Eyebrow depilation.0.35 Lacquer.0 25\" 9.Section 123 will l>c replaced by the follow irtg: \"123.Ratio of apprentices: There shall be no more than two (2) apprentices for each qualified hairdresser, in any one salon.\" Publication of this notice does not make bind* ing the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can l>e made binding Only by an Order in Council, which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider objections which interested parties may wish to make; objections should l>c submitted in duplicate if possible.G Kit a It 1) Tit KM III.ay.De put y Minister of Labour.Department of Labour.Québec, dune 11.1900.16449-0 Avis dc modification Barbiers, coiffeurs, coiffeuses \u2014 Sherbrooke L'honorable Carrier Fortin, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q.1964, chapitre 143).que les parties contractantes à la convention collective «le travail rendue obligatoire par le décret numéro 255 «lu 5 mars 1953 et amendements, relatif aux métiers de barbier, coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Sherbrooke, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret; 1° Le nom «le « L'Association «les Matties et Artisans-barbiers du district de St-François » apparaissant comme partie contractante de première part sera remplacé par: « L'Association «les Coiffeurs pour hommes du District dc St-François ».2° L'article 110 sera remplacé par le suivant: « 110.Le salaire minimum pour les employés permanents et surnuméraires est le suivant: u) Permanent: Coiffeur pour hommes: Classe « A ».\" 832.00 par semaine plus 00% tics recettes de son travail excédant 845.00 par semaine.Coiffeur pour hommes: Classe « B ¦ : 831.00 par semaine plus 50% ties recettes tie son travail excédant $44.00 par semaine.Notice of amendment Barbcring and hairdressing trades \u2014 Sherbrooke Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q.1904, chapter 143), the Honourable Carrier Fortin, Minister of Lalxnir, hereby gives notice that the contracting parties to the collective labour agreement respecting the Barbcring and Hairdressing trades in the Sherbrooke region (made binding by decree number 255 of March 5, 1953 and amendment-^ have petitioned him to submit the following amendments to the saitl decree to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council : 1.The name of \"VAssociation des Maîtres et Artùians-barbiers du district de St-François\".mentioned as contracting party of the first part will be replaced by that of \"L'Association des Coiffeurs pour hommes du District de St-François\" 2.Section 110 will be superseded by the following: \"116.Minimum wages for permanent am! occasional employees are as follows : (o) Permanent: Men's hairdresser, class \"A\": $32.00 a week, plus 60% of his work's receipts over $45.00 a week.Men's hairdresser, class \"B\": $31.00 a week, plus 50% of his work's receipts over $44.00 a week. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, 1966, Vol.98, No.98 3209 Surnuméraire: ' ni fleur pour hommes: ('lasse « A ».' ¦S3.00 pur jour plus 00% «les recettes «le s«»n travail excédant $4.50 par jour.IOiffeur pour hommes: Classe « B »: 12.50 par jour plus 50% «les recettes «le son travail escétlant $4.00 par jour, r) Apprenti: l Oiffeur pour hommes.1ère ftllllee: $22.00 plus 40% sur l'excédant de $32.00; 3ème semestre: $25.00 plus 40% sur l'excédant «le $35.00; lème semestre: $27.00 plus 40% sur l'excédant «le $37.00; 5ème semestre: $28.00 plus 40% sur l'excédant de $38.00; Oèmc semestre: $31.00 plus 40% sur l'excédant de $41.00.» 3° L'article 117 sera remplacé par le suivant: - 117.Durée du travail: Pour toutes les opérations de coiffeurs pour hommes.h\\s heures régu-lièrefl de travail sont réparties «le la façon suivante : Zone I Lundi: Chômé toute la journée.Mardi, mercredi, jeudi: 8.30 a.m.à 0 p.m.; Vendredi: 8.80 a.m.ù 0 p.m.; Samedi et veilles de fêtes: 8.30 a.m.à 5 p.m.Exception*: 1 ) Les heures de travail sont prolongées jusqu'à 9 p.m.le Jeudi Saint.2) Le hindi de la Semaine Sainte et le lund1 précédant la fête «le Noël: 8.30 a.m.à 0 p.m.3) Dans les villes de Sherbrooke, Lcnnoxville, Bromptonville et le territoire compris dans un rayon de dix (10) milles «le leurs limites respectives, le travail peut se prolonger jusqu'à 9 p.m.les jours «l'ouverture «lu Marché Lansdownc.4) Dans les villes de Magog, Asbestos, Danville et le territsire compris dans un rayon «le dix (10) milles de leurs limites respectives, les heures «le travail sont les suivantes: Lundi: Chômé toute la journée; Mardi, mercredi, jeudi: Vendredi: Samedi: 9 a.m.à 0 p.m.9 a.m.à 9 p.m.9 a.m.à 5 p.m.Zone 11 Lundi: Chômé toute la journée; Mardi, mercredi, jeudi: 8.30 a.m.à 6 p.m.Vendredi: 8.30 a.m.à 9 p.m.; Samedi et veilles de fêtes: 8.30 a.m.à 0 p.m.Exception*: 1) Dans la ville de Lac Mégantic et un rayon de cinq (5) milles de ses limites, la durée du travail est prolongée jusqu'à S p.m.les 20-21-22 décembre lorsqu'ouvrables.2) Dans la ville de Rock Island et les municipalités de Beebe Plain et Stanstead et un rayon «le cinq (5) milles de leurs limites, les heures sont les suivantes: Lundi, mercredi et veiulredi: 8.30 a.m.à 0 p.m.Mardi: 8.30 a.m.à 12 a.m.(midi) Jeudi et samedi: 8.30 a.m.à 9 p.m.(b) Occasional: Men's hairdresser, class \"A\": $3.00 a ilay, plus 60% of his work's receipts over $4.50 a day.Men's hairdresser, class \"B\": $2.50 a day, plus 50% of his work's receipts over $4.00 a day.(c) Apprentice: Men's hairdresser: 1st year: $22.00, plus 40% of any amount over $32.00; 3rd six months: $25.00, plus 40%, of any amount over $35.00; 4th six months: $27.00, plus 40% of any amount over $37.00; 5th six months: $28.00, plus 40% of any amount over $.38.00; 0th six months: $31.00, plus 40% of any - amount over $41.00.\" 3.Section 117 will be replaced by the following: \"117.Hours of work: Stamlartl working hours are scheduled as follows for all men's hairdressing work : Zone I Monday: non-working ilay.Tuesday, Wednesday, Thursday: 8:30 a.m.to 0:00 p.m.Friday: 8:30 a.m.to 9:00 p.m.Satunlay and eves of holidays: 8:30 a.m.to 5:00 p.m.Exceptions: (1) On Holy Thursday, working hours arc extemled until 9:00 p.m.(2) On Monday of Holy Week and the Monday before Christmas: 8:30 a.m.to 0:00 p.m.(3) In Sherbrooke, Lcnnoxville, Bromptonville ami the territory located within a 10-mile radius from their respective limits, work may l>e extended until 9:00 p.m.when the Landsdowne Market is open.(4) Working hours are as follows in Magog, Asbestos, Danville ami the territory located within a 10-mile radius from their respective limits: Monday : non-wo r k ing day.Tuesday, Wednesday, Thursday: 9:00 a.m.to 6:00 p.m.Friday: 9:00 a.m.to 9:00 p.m.Saturday: 9:00 a.m.to 5:00 p.m.Zone 11 Monday: non-working day.Tuesday, Wednesday, Thursday: 8:30 a.m.to 0:00 p.m.Friday: 8:30 a.m.to 9:00 p.m.Saturday and eves of holidays: 8:30 a.m.to 6:00 p.m.Exceptions: (1) In the town of Lac Mégantic and a 5-mile radius from its limits, working hours are extended to 8:00 p.m.whenever December 20, 21, 22 arc working days.(2) In the town of Rock Island ami the municipalities of Beebe Plain and Stanstead and a 5-mile radius from their limits, working hours are as follows: Monday, Wednesday and Friday : 8:30 a.m.to 6:00 p.m.Tuesday: 8:30 a.m.to noon Thursday and Saturdav: 8:30 a.m.to 9:00 p.m. .{210 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Il juin 19GG, 98' année, n° 23 8) À East-Angusi Bury, Cookshiro et Sawyer* villr et «lans un rayon «le cinq (>r>) milles c designated as Title I.2.The following text, designated as Title II.will Ik* added to Title I: Title II Social Security Plan Part I Division 1 Section 1: In this title, unless the context requires otherwise, the meaning of the following terms is given below: Decree: This word designates decree number 1743 of July 11, 1941 ami amendments, respecting the Building trades in the Chicoutimi Lac St-Jean ami BoberVal regions.Contracting parties: The words designate //Association des Constructeurs Saguenay, Lac St-Jean Inc.the Corporation of Master Pips Mechanics of Quél>ec (Saguenay \u2014 Liu* St-Jean section).Le Syndicat National des Travailleurs de la ('onstruction du Lac St-Jean.Le Conseil des Métiers de la Construction Chicoutiini Lac St-Jean 3212 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 11 juin 1966, 98' année, n\" 28 ('«instruction Chicoutiini Luc St-.Icun » et «La Fédération Nationale «les Syndicats «lu Bâtiment «¦t du Mois Ouvré Inc.».Régime de Sécurité Sociale: Ces int>ts désignent le régime établi en vertu «lu prés«-nt titre jxuir créer un régime de rente de retraite et un régime d'ussuraiHT-vic collective.Il est désigné « Régime «le Sécurité Sociale «les régions «le Chicoutiini.Lac St-Jean et Rohcrval ».Fonds de Sécurité Sociale: Ces m«>ts désignent le fonds créé en vertu de l'article 2 «lu présent titre pour les employés «le l'industrie «le la construction «lans le champ d'application territorial du présent décret.Prestations de Sécurité Sociale: Ces mots «lési-gnent les prestations établies par et «lans le présent titre.Comité de Sécurité Sociale: Ces mots désignent le comité formé en vertu de la section 4 du présent titre qui est appelé « ('«unité «le Sécurité Sociale «les régions «le Chicoutiini.Lac St-Jean et RoIkt-val ».Employe: Ce mot désigne tout employé payé à l'heure visé au titre I, sauf les employés «lu métier «l'électricité.Ce mot désigne aussi, s'il y a lieu, t«mt employé cial Security Committee, pursuant to section 16 of this title.Employees'' Representative: These words mean any person, ami successors, appointed to represent employees on the Social Security Sub-Committee, pursuant to section 17 of this title.Group Life Insurance Plan: The words mean the Group Life Insurance Plan established in Part IV of this title and underwritten by a life insurance company.Group Life Insurance Fund: These words mean the Group Life Insurance Fund of the building trades the Chicoutiini, Lac St-Jean ami Rohcrval regions, set up in accordance with section 59 of this title and administered by a trust company in accordance with a trust agreement signed by the Joint Committee and the trust company or administered by a life insurance company in accordance with a group life insurance policy signed by the Joint Committee and the life insurance company. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, 1906, Vol.OS, A'o.>>j 3218 Régime Je rente Je retraite: Ces mots désignent |r régime de rente de retraite institué par la Lotie III du présent titre.Caisse Je retraite: Ces mots désignent la Caisse de retraite de l'industrie de la construction des régions de Chicoutiini.Lac St-.Iean et Rolierval i i.-t'v conformément ù l'urtiele 4li du présent titre il administrée par une compagnie «le fidéicommis conformément à l'acte «le fiducie signé par le ( ur que le paiement soit l'ail à tout parent naturel ou allié «le l'employé décédé ou à toute personne «jui.«le l'avis «lu ('«unité de Sécurité Sociale, aura «Iroit en justice au paiement parce qu'elle attra encouru des frais en rapport avec la subsistance, les frais funéraires et ceux de dernière maladie, l'enterrement «le l'employé OU les soins médicaux fournis à l'employé, ou «|ui réclamera une partie de la succession en rapport avec ces frais.Retraité: ( '«\u2022 mot désigne toute personne recevant «les prestations «le retraite conformément à la Partie III «lu présent titre.Compagnie de fidéicommis: Ces mots «h-.signciil toute compagnie «le fidéicommis détenant «lans la province «le Québec un certificat d'enregistrement émis par le Ministre «les Finances.Compagnie d'assuranec-rie ou assureur: Ces mots désignent toute société ou compagnie d'assurance-vie détenant dans la province de Québec un certificat «l'enregistrement et un permis émis par le Ministre des Finances.Comité Paritaire: Ces mots «h'-signent le Comité Paritaire «le l'industrie «le la construction «les régions «le Chicoutiini, Lac St-.Iean et Rohcrval.Heure de travail: Ces mots désignent toute heure où l'employé est effectivement au travail sans considération du taux puyé.Ils désignent également toute fraction d'heure «l'une demi-lieure ou plus, laquelle est considérée aux fins «lu présent titre comme une heure complète.Les fractions d'heure ne sont pas cumulatives «l'une période «le paie à l'autre.Cependant, lorsque la participation est volontaire, les heures «le travail de l'employé exécutant des travaux hors du champ d'application territorial sont celles effectivement exécutées sans considération du taux payé.Lorsque la participation volontaire provient «lu fait «pie l'employé est hors du chump «l'application professionnel, les heures de travail sont celles qui sont définies comme étant la durée «le travail par semaine au titre I «lu présent décret.Retirement Pension Planj These words mean the Retirement Pension Plan established by Part III of this title.Retirement Fund: These words mean the Retirement Fund of the building trades in the Chicoutiini, Lac St .lean and Rohcrval regions, set up in accordance with section 43 of this title and administered by a trust company in accordance with a trust agreement signed by the Joint Committee ami the trusted or administered by a life insurance company in accordance with u retirement contract signed by the Joint Committee and the life insurance company.Death Benefits: These wor«ls mean the death benefits provided for in Part III of this title.Retirement Benefits: These words mean the retirement pension benefits provided for in Part III of this title.Beneficiary: This wor«l means any person who is designated from time to time hy written notice to the Joint Committee by an employee or former employee to receive social security benefits, if any, umler this social security plan in the event of the death of the employee or former employee.If 00 person is so designated by the employee or former employee, or if the person so designated predeccase«l the employée or former employee, the lieneficiary shall be the estate of the employee or former employee.However, the Social Security Committee shall have the power to direct that payment Ik* made to any person related by blood or marriage to the decased employee or to any person appearing to the Social Security Committee to lie cquilably entitled to payment by reason of having incurred expenses for the maintenance, burial, last illness of the employee or medical attemlance given to the employee, or who elaims a portion of the estate in connection with such expenses.Pensioner: This word means any person receiving retirement benefits pursuant to Part III of this title.Trust Company: These words mean a trust company holding, in the Province of Québec, u registration certificate issued by the Minister of Finance.Life Insurance Company or Underwriter: These words mean a life insurance company or society holding, in the Province of Québec, a registration certificate and permit issued by the Minister of Finance.Joint Committee: These words mean le Comité paritaire de l'industrie de la construction des régions de Chicoutiini, Lac St-Jean et Roberval.Hour of Work: These words mean any hour actually worked, regardless of the rate of pay.They also mean any fraction of one-half hour «>r more, which is considered for the purposes of the present title to lie one complete hour.However, fractions of an hour will not lie cumulative from ane pay period to another.When participation is voluntary, the hours an employee lias worked outside the territorial jurisdiction arc those worked regardless of the rate paid.When voluntary participation is due to the fact that the employee is outside the professional jurisdiction, wording hours are those defined as the standard work week in Title I of this decree. 321-1 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, // juin 106*0, 98' année.»\u2022 $$ Contribution: Ce mot désigne le montant «l'argent dû, par l'employeur et par l'employé en vue de constituer le Komis de Sécurité Socinlc.Cotisation: Ce mot désigne le montant «l'argent reçu par le Comité Paritaire en vue «le constituer le ronds «le Sécurité Social*-.Cotisations accumulées des employés: Ces nuits désignent les cotisations des employés au Ponds de Sécurité Sociale plus uu intérêt composé établi à trois pour cent (395 ) par année.L'intérêt sur chaque cotisation «le (employé sera calculé à partis «le la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations «le l'employé ont été reçues jusqu'au premier jour «lu mois dans lequel un remboursement est effectué ou, «lans lé cas «l'un ancien employé qui recevait des prestations de retraite, jusqu'à la «late du premier paiement mensuel «!«¦ ses prestations de retrait»-.Section 2 Fonds de Sécurité Sociulc Article 2: Un fonds «le Sécurité Sociale est par les présentes créé afin f the calendar year for whu-h the employee assessment is te.ceived, up to the first day of the month in which a refund is paid «>r, in tlie cms of a former employee who was in receipt of retirement benefits, to the «lue dute of the first monthly payment of his retirement benefits.Division 2 Social Security Fund Section ,': A Social Security Fund is hereby set up t«i provide social security benefits, either pension benefits or death benefits, for tin- etll ployees «if the building trades in the Chicoutiini, Lac St-Jean and Rohcrval regions.Such fund shall come into force when an Order in Council, rendering obligatory the provisions of tins title, is published in the Québec Official (lazette.Sin h fund shall supply: the Retirement Fund ami the Group Life Insurance Fund.Section 8: The Joint Committee is horclo designated as the body to receive contributions from employers and employees.It is vested with all rights, title and interest in ami to the Social Security Fund pursuant to the uses, duties and restrictions s«-t forth in this title.Division 3 Contributions and assessments Section .',: As of July 1, 1966, every employe! of employees shall deduct from the wages earned by each of his employees the sum of five cents (5é) for each hour Worked by the said employee*.This deduction shall constitute the employe contributions t the Social Security Fund.Every employer f employees shall contribute to the social Security Fund for each of his employees the sum of five cents (5é) f«>r each hour worked by the said employees.Section ô: Every employer shall pay to the Joint Committee not later than the fifteenth (15th) of each mouth, the total contributions deducted from employee's wages in the previous month, plus his own contribution.Section (>: If an employer, contrary to section 5.fails to remit the contributions to the Joint Committee, the latter shall have the right to use all legal measures and sue the employer f«>r and on behalf of the employees concerne»! for the purpose of recovering the contributions together with any penalty incurred by the said employer as a result of his default; such recovery and legal action being enforced in accordance with section 20 of the Collective Agreement Decrees Act. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June //, 19GG, Vol.98, No.23 8315 Aux fini de l'article 37 de lu Loi des Décrets ¦i( Convention Collective) lu date «l'échéance «le la remise des contributions, pour chaque* employé, sera le 1er janvier suivant.Article 7: Aueun employeur ne |>cut se libérer l« son obligation «le remettre au Comité Paritaire les contributions stipulées en pavant directement les«lites contributions aux employés.Toute convention contraire aux dispositions du présent titre, accordant à un employé «les conditions différentes «le celles mentionnées a\" présent htr«\\ «m «pi lerr soient moins favorables, sera non avenue «'t nulle de nullité absolue.Article S: Tout employé «loit déclarer au ( \"«unité Paritaire son nom.l'adresse «le son domicile, sou numéro d'immatriculation d'assurance- -iM-iule, sa «late de naissance, son métier ou emploi, son étut mat riinonial, le nombre de ses infants dépendants Agés de moins de vingt et un (21) ans, le nom, l'adresse et le lien de parenté île son bénéficiaire, s'il y en a un, la «lute a'i laquelle il donne ces renseignements et sa signature.Il «loit fournir ces renseignements: a) uu 1er juillet I960; b) au début «le chaque année civile, par la suite, m des changements à la dé-eluratiou originale sont survenus pendant l'année pnVédcntc.Article .9: Le Comité Puritaire «loit fournir gratuitement ù tout employeur «les formules appropriées, lesquelles devront être remises par ¦ haqUC employeur uux employés.Toutefois, la pénurie «le telles formules ne libère pas l'employeur «le son obligation «!«\u2022 n'identifier par écrit auprès «lu Comité Paritaire.Article 10: Tout employeur «loit: a) indiquer sur chaque liste «le paie le montant d'argent déduit du salaire «le chacun de ses employés pour les fins du Fonds «le Sécurité Sociale pour la période couverte par ladite liste de paie; b) fournir avec chaque paiement «le contributions SU Fonds «le Sécurité Sociale une «léclara-lion annexée à un extrait OU à une copie «le lu liste de paie mentionnant: 1.le nom et l'adresse audit employeur; 2.lu période «le paie couverte par chaque liste; 3.le nom «le famille et le prénom «le chaque employé} 4.le numéro d'immatriculation d'assurance-sociale «le chaque employé: 5.le montant des contributions au Fonds de Sécurité Sociulc accumulées pendant la période couverte par ladite liste «le paie en regard de chacun «les employés; (1.le total «le ces montants; 7.une attestation écrite de l'exactitude et «le la véracité «les renseignements founds sous la signature «le l'employeur lui-même ou «le son représentant autorisé.Article 11: Le Comité Paritaire doit, sur demande, fournir gratuitement ù chaque employeur les formules appropries sur lesquelles les présents renseignements peuvent être donnés «'t.si les listes produites par un employeur sont trouvées insuffisantes, le Comité Paritaire peut enjoindre cet employeur «l'utiliser les formules spécialement préparées à Cet effet et mises à sa disposition.Article 12: A-Le Comité Paritaire ou son représentant «loit: a) tenir des registres, ou faire tenir tics registres pur une autre institution, pourvu que copie For the purposes of section 37 of the Collective Agreement Decrees Act.the due date for the remittance of contributions for each employee shall be the following January 1.Section 7: No employer may discharge himself «>f his obligation to remit the stipulated contributions to the Joint Committee by paying the said contributions «lireetly t«> employees.Any agreement contrary to the provisions of this title granting an employee conditions different from or less favourable than those set forth in this title shall be nrll and void.Section S: Kvery employee must notify the Joint Committee of his name, his home address, his social insurance uumher.his date of birth, his trade or occupation, his marital status, the number of his dependent children umler twenty-one (21); the name, address and relationship of his bénéficier}', if any; the date on which lie gives this information ami his signature.He must submit this information: (a) on July 1.1966; (b) at the beginning of each calendar year thereafter, in the event changes have OCCUred in the original statement during the preceding year.Section !l: The Joint Commit tee shall make forms available to any employer f«)r this purpose and every employer shall supply such forms t«> each employee.However, the lack of such forms does not relieve the employer of his obligation to identify himself to the Joint Committee in writing.Section 10: Kvery employer shall: (a) show on each payroll the amount of money deducted from each employee's salary for the Social Security Fund, for the period covered by the said payroll; (/>) furnish with each payment of contributions to the Social Security Fund, a statement with an extract from or a duplicate of the actual payroll showing: 1.the name and address of the said employer: 2.the pay period covered by the payroll, 3.the family name ami given name of each employee; 4.each employee's Social Insurance number; 5.the amount of contirbutions to the Social Security Fund accumulated during the period covered by the saitl payroll in respect of each employee; l>.the total of such amounts; 7.a written certificate attesting the accuracy r reporting the foregoing information and may.if it determines that the statement submitted by the employer is unsatisfactory, direct that the employer complete the forms especially prepared for this purpose and made available by the Joint Committee.Section 12: A - The Joint Committee or its representative shall: (a) keep records or have same kept by another firm (provided that such records the available 3216 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Il juin tm, 9H< année, n° 28 «le ces registres suit dis|M>nible uu bureau principal ù Cliicoutiini.mentionnant ù l'égard de chàquc employé: 1.les renseignements fournis par chaque employé visé à l'article S; et 2.le nom et l'adresse de l'employeur ou des employeurs qui ont payé des cotisations au nom de chaque employé; et 8.le montant de ces cotisations, la date de leur reception ou la période de paie pour laquelle elles se sont accumulées; b) danl les trois premiers mois de chaque année, remettre ou faire remettre n chaque employé un relevé des cotisations en son nom pour la période de doute (12) mois as terminant le .'Il décembre de l'année précédente.M Le ( 'omité Paritaire doit prendre toutes mesures qu'il juge appropriée! afin de percevoir de l'employeur les contributions qui deviendront dues au ponds de Sécurité Sociale, au crédit de l'employé.Article 13: Le ('«unité Paritaire divise toutes les cotisations en deux montants distincts «'t lei remet au Comité «le Sécurité Sociale.In «le ces montants distincts est Formé «les cotisations de tout employéet «les (piat recin«|uièmc (4/5) «lescoti-rations «les employeurs.( 'e montant «loit être versé «lans la Caisse de retraite.L'autre de ces montants, formé d'un cinquième (1/5) des cotisations de tout employeur, est afférent à la Caisse d'assurance-vie collective et doit y être versé.Pantin II Section 4 Le Comité de Sécurité Sociale Article l.'t: Dès la publication dans la Gazette officielle de Québec «le l'arrêté en conseil rendant obligatoires les dispositions du présent titre, le Comité Paritaire doit procéder à la formation «l'un Comité de Sécurité Sociale et à la nomination «le représentants patronaux et ouvriers, selon la procédure établie aux article Hi et 17 «le ce titre.Article 15: Le ('«muté de Sécurité Scciale doit être formé «le six ((>) membres dont trois (3) devront être des représentants «les employés et trois (3) «les représentants «les employeurs.Article 16: Chaque représentant des employeurs devra être nommé pur le Comité Paritaire selon la procédure suivante: a) Deux (2) des représentants «les employeurs devront être désignés par « L'Association des Constructeurs Sagnenay, Lac St-Jean Inc.v>.l'n certificat «le désignation attesté par un officier autorisé «le cette association sera remis au Comité paritaire.Le troisième (3e) représentant «les employeurs devra être désigné par « La Corporation «les Maîtres Mécaniciens en Tuyauterie «lu Québec (Section Saguenay-Lac St-Jean) ».Un certificat de désignation attesté par un officier autorisé de cette corporation sera remis au Comité paritaire.b) Le Comité Paritaire «loit, à ses assemblées ordinaires, nommer les représentants ainsi dési-gnés et les informer officiellement de leur nomination.c) Chaque représent ainsi désigné et nommé entre en fonction au moment de son acceptation de la nomination faite et reçoit une indemnité à titre «le compensation pour ses services (jetons «le présence et frais).ut the Chicoutiini keadquarters), mentioning, in respect of eueh employee: 1.the information supplied by esc h employee mentioned in section B: 2.the name and address of the employer or employers Who paid assessments on each em ployee's behalf ; 3.the amount of such assessments, the date they were received ami or the pay period for which they huve accumulated.(b) during the first three months of each year, remit or have remitted t«> each employee a state- ment of assessments received in his name for the twelve (12) month period ending on the previous December 31.B - The Joint Committee shall take all neces sary steps to collect from the employer, contri butions that will become «lue to the Social Security Fund, to the employee's credit.Section 13: The Joint Committee shall divide the amount of assessments received into two separate amounts ami shall remit same to the Social Security Committee.Due such amount consists of the assessments of every employee ami of four-fifths (4/5) of the assessments «>! the employers.Such amount shall be deposited in the Retirement Fund.The other amount, consisting of one-fifth (I/o) of the assessments of every employer, belongs to the Group Life Insurance Fund and shall be deposited therein Past H Division 4 The Social Security Committee Section H: Immediately after an Order in Council rentlering obligatory the provisions of this title is published in the Québec Official Gazette.the Joint Committee shall proceed with the creation of a Social Security Committee ami the appointment of employers' and employees' representatives according to the procedure stipulated in section 10 and 17 of this title.Section 15: The Social Security Sub-Committee shall be made up of six (0) members; three (3) shall l>e employees' representatives and three (3) shall l>e employers' representatives.Section 16: Each employers' representative shall be apointcd by the Joint Committee according to the following procedure : (a) Two employers' representatives shall be designated by L'Association des Constructeurs Saguenay, Lac St-Jean Inc.A certificate of designation certified by an authorized officer of this association shall be filed with the Joint.Committee.The thin! (3rd) representative shall Ik-designated by the Corporation of Master Pipe Mechanics of Québec (Saguenay - Lac St-Jean section).A certificate of designation certified by an authorized officer of this corporation shall l>e filed with the Joint Committee.(b) The Joint Committee shall, at its regular meetings, appoint the representatives thus designated and officially advise them of their appointment.(c) Each representative so designated ami appointed shall take office upon accepting the nomination.As such, he shall receive a compensation for his services (attendance tokens and expenses). QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June U, 19W, Vol.9H, No.93 3217 Article 17: (\".'Inique représentant des employés devra être nommé par le Comité Paritaire selon la procédure suivante: a) Les trois (3) représentants des employés sont désignés comme il suit: l'n (1) représentant devra être désigné pur « I/' Conseil des Métiers de la Construction Chicoutiini Lac St-.Iean; un certificat de désignation attesté par un officier autorité du dit conseil seru remis au Comité paritaire, l'n deuxième (2e) sera désigné conjointement par « Le Syndicat National des Travailleurs de la Construction de Chicoutiini », « Ix* Syndicat dot Travailleurs de lu Construction du Lac St-Jean » et « Lu Fédération Nationale des Syndicats du Bâtiment et du Bois Ouvré Inc.», Un certificat de désignation attesté pur un officier autorité «lu « Syndicat National «les Travailleurs de lu Construction «le Chicoutiini », du Syndicat «les Travailleurs de la Construction f the employers representatives shall he cast by a majority of the employers' representatives present ami voting.In the event any matter presented for decision cannot be decided because of a tie vote, the mutter shall remain in status quo pending arbitration as set forth in division 7 hereof, unless it be decided, by unanimous vote, t«> dismiss the mutter.Section 28: Any decision taken by the Social Security Committee shall l>e entered in tin-minutes of the meeting during which the decision was taken.A true copy of the minutes of uny meeting shall l>e forwarded by the secretary, to the Joint < 'onunit tee, at the l>eginning of the following month.Division 7 Arbitration Section 89: In the event the Social Security Committee cannot decide any matter or resolve any dispute because of a tie vote or in the event decisions cannot be made because of the la«-k of a quorum at two successive meetings of the Social Security Committee, then and in either of such events, the Social Security Committee shall attempt t«> select an impartial arbitrator t«> hear and determine the matter, issue or dispute.Section 30: If the representatives cannot agree on an impartial arbitrator within five (\u2022\">) culemlar days from the day they have attempted to effectuate his selection, an impartial arbitrator shall be designated by the Magistrate's Court of the «listrict of Chicoutimi.Any two (2) representatives may request that the Magistrate's Court of the district of Chicoutimi designate an arbitrator.Section $1: A hearing on the disputed matter shall Ik> held within ten (10) days from the date the arbitrator has l>een selected or designated.The decision or award of the arbitrator shall be in writing and shall he final and binding upon nil parties and persons concerned ami shall be made within ten (10) working days after the arbitrator receives all the evidence.The arbitrator, in his decision or award, shall he bound by the provisions of this title ami shall have neither power nor authority to a«l«i or subtract from this title or to change or modify the provisions hereof.Division h Limitation of liability Section 32: Neither the Social Security Committee nor any representative shall Ix* liable for any error of judgment or for any loss arising out of any act or omission in the administration of the Retirement Fund ami of the Croup Life Insurance Fund, nor shall any of them Ik-personally liable for any liability or debt of the Social Security Committee contracted or incurred by such Committee, nor for any other liability arising in connection with the aihninistrution or the existence of the Social Security Fund.However, nothing herein shall except the representatives or any one «)f them from liability, obliga- 3220 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 11 juin I960, 98' année, n° 23 effet «le soustraire ers représentants à la responsabilité résultant d'obligations OU defies produites par leur action OU omission accomplie ou subie de mauvaise foi OU par négligence grossière ou inconduite délibérée.Le Comité Paritaire et les représentants de ce Comité ne seront pas tenus personnellement responsables d'aUCUne erreur de jugement ni d'aucune perte résultant de tout acte ou de toute omission concernant la perception des contributions ni de toute autre obligation résultant ou étant attachée à l'administration dei dossiers du Régime de Sécurité Sociale et ils ne seront personnellement responsables d'aucune obligation OU dette du < 'oun'té ver the construction trades in til*- Province of Québec, any retirement transfer agreement.The purpose «»f such a transfer agreement is to enable the transfer * if assessments from one social security fund when' uu employee was covered to another social security fund where an employee becomes covered.It thus assures employees of the cons-traction industry of the Province of Québec a continuous participation as well as a preservation «'f their rights and privileges in a social security plan.This agreement shall be general in nature and shall apply to all and not t«» one particular case.This agreement shall only lie possible when the transfer is made to another retirement fund.When such an agreement is accepted, it shall be sumitted to every Joinl Committee concerned for signing purposes.Com «>f such agreement duly signed by the parties shall be fil«'«l without delay with the Department of Labour and the Québec Pension Board.(e) to interpret all the ambiguous or doubtful provisions or terms of this title.Any interpretation given in good faith by the Social Security ('«munittec shall bind all concerned; (/) to employ responsible officers and advisers, personnel for administration, office ami secrcta rial ami other employees whose services may I» required for the current administration of the two funds and for the proper operation of tile Social Security Plan.(g) to authorize any of its agents to represent il iu the performance or carrying out of any duty under the jurisdiction of the said Committee; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 11, 1966, Vol.US, Mo, tS 3223 In da faire les règlements pour Mil fonctionnement interne et l'exercice des devoirs, obligations el droits à lui conférés, le tout sujet ù la Loi des Décrets de Convention Collective et un présent I il re.de louer ou d'Acheter des bureaux administratifs, de l'ameublement, «les fournitures et .-nitres choses essentielles ù l'administration du Régime de Sécurité Sociale.r d'utiliser les actifs de la Caisse «le retrait»-sux fins suivantes: 1.payer les primes ù lu compugnie d'assurunec-ii, s'il y en a, avec laquelle un contrat «le rente île retraite est signé, ou payer les prestations de retraite à même la Caisse; 2.s'assurer «lu paiement «les prestations prévues aux termes du régime «le rente «le retraites 3.payer toutes les dépenses raisonnables et iieeessainvs encourues par rétablissement et l'organisation «le la Caisse de retraite et du régime de rente «le retraite; i.payer ttnites dépenses raisonnables et nécessaires, y compris les salaires, coûts et honoraires encourus par le Comité de Sécurité Sociale en raison «lu maintien et «le l'administration de la ( aisse «le retraite et «lu régime «le rente «le retraite ainsi «pie le coût «le l'admini>tration «les registres exigés en vertu «le l'article 12-A «lu présent titre: .\").payer toutes taxes réelles et personnelles, impôts sur le revenu et autres tnxcs ou cotisations de toutes SOrtes imposées en vertu «les lois exis-i antes ou futures sur la ( laisse «le retraite OU à son -ujet; 0.payer aux représentants membres du ( !omité de Sécurité Sociale une indemnité raisonnable et toutes dépenses encourues pur lesdits représentants «lans l'accomplissement «les tâches qui leur -ont imposées par le présent titre, pourvu que le paiement «le ces déboursés soit approuvé par le ( «unité «le Sécurité Sociale et conforme aux dispositions «les articles 10 et 17 du present titre./¦\u2022) «l'utiliser les actifs de la Caisse d'assurance-vie collective aux fins suivantes: 1.payer les primes à la compagnie d'assurance-vie «pli assume le risque; 2.s'assurer «lu paiement «les prestations d'assu-rance-vie collective prévues aux termes «lu regime d'assurance-vie collective; 3.payer toutes les dépenses raisonnables et nécessaires encourues par l'établissement et l'organisation «le la Caisse «l'assurance-vic collec-live et du régime «l'assurance-vic collective; l.payer toutes dépenses raisonnables et nécessaires, y compris les salaires, coûts et honoraires encourus par le Comité de Sécurité Sociale en raison «lu maintien et «le l'administration «le la Caisse «l'assurance-vic collective et «lu regime d'assurance-vic collective ainsi que le coût de l'administration des registres exigés en vertu de l'article 12-A «lu présent titre; ô.payer toutes taxes réelles et personnelles, impôts sur le revenu et autres taxes ou cotisations \u2022le toutes sortes imposées en vertu «les lois existantes ou futures sur la Caisse «l'assurance-vic collective ou à son sujet : 0.payer aux représentants membres du Comité de Sécurité Sociale une imlemnité raisonnable et toutes dépenses encourues par lcs«lits représentants «lans l'accomplissement «les tâches qui leur sont imposées par le présent titre, pourvu «pie le paiement «le ces déboursés soit approuvé par le Comité «le Sécurité Sociale et conforme aux dispositions «les articles 10 et 17 «lu présent titre.(h) to pass any by laws for its internal operation and for the exercise of the duties, obligations ami rights conferred Upon it, in pursuance of the Collective Agreement Decrees Act ami of the present title; (») to rent or buy office spu«-c, furniture, etiuip- menl and other essential requisites for the administration of the So«-iuI Security Plan; (j) to use the assets of the Retirement Fund for the following purposes: 1.to pay premiums to the life insuram-e company, if any, with which a retirement pension «\u2022ontruct is sigue«l or to pay the benefits from the Fund; 2.to provide for the payment of all the Ik-uc- hts payable umler the terms «>f tin- Retirement Pension Plun: 3.to pay all reasonable and necessary excuses for the establishment ami organization «»f the Retirement Fund and the Retirement Pension Plun; 4.to pay nil reasonable and necessary expenses including salaries, costs and fees incurred by the Social Security Committee in connection wth the maintenance and operation «>f Retirement Fund, the Retirement Pension Plan, as well as the OOSt of record maintenance stipulated in section 12-A of this title; 5.to pay all real ami personal taxes, income tax ami other taxes «>r assessments all kinds levied or assessed under existing or future laws upon or in respect to the Retirement Fund; c».to pay the representatives (members of the Social Security Committee) a fair ami reasonable compensation and all expenses incurred by the said representatives in the jK-rfonnancc of their duties hereunder, provided the payment for said expenditures is approved by the Social Security Committee and is in accordance with the provisions of sections 10 ami 17 of this title.(k) to use the assets of the Group Life Insurunce Fund for the following purposes: 1.to pay the premium to the underwriting life insurance company; 2.to see to the payment of all group life insurance benefits payable umler the tenus of the Croup Life Insurance Plan; 3.pay all reasonable and necessary exj)cnscs incurred in the setting up ami implementation »>f the Group Life Insurunce Plan and Fund.4.to pay all reasonable ami necessary expenses salaries, costs ami fees incurred by the Social Security Committee in connection with the maintenance and operation of the Group Life Insurance Fund ami Plan as well as the records required under section 12-A of this title; f>.to pay all real ami personal taxes, income tax ami other taxes or assessments of all kinds levied or assessed under existing or future laws upon or in respect to the Group Life Insurance Fund ; 6.to pay the representatives (members of the Social Security Committee) a fair ami reasonable compensation and all expenses incurred in the performance of their duties herein stipulated, provided payment for sai«l expenditures is approved by the Social Security Committee and concurs with the provisions of sections 10 and 17 of this title. 3221 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, II juin 19(16, 98' année, n\" 23 l) do fournir à lu compagnie de fideiconunis ou à lu compagnie d'ussurauce-vie ou aux deux à la l'ois tout renseignement et toute formule (pie pourraient exiger ceux-ci à l'égard du paiement des prestations visées duns le Régime «le S«:«-u-rité Sociale.Article .'A: L*' Comité de Sécurité Sociale aura le pouvoir de reviser les dispositions du Régime de Sécurité Sociale de temps à autre et de recommander aux parties contractantes tels change* ment s.modifications et amendements audit Régime que le Comité «le Sécurité Sociulc estimera désirables.Toute modifient ion apportée à la contribution ou au montant «le prestations de sécurité sociale doit être appuyée par un rapport «le Tact nuire quant à la suffisance «le la contribution pour assurer le paiement «les prestations de sécurité sociale.Partie m Régime de rente tic retraite Se«-tion 1(1 tinsse de retraite f the contributions t«> assure the payment of the social security benefits.Past III Retirement pension plan Division 10 Retirement Fund of the Building Trade in tin Chicoutimi, Lac St-Aean and Rohcrval region* Section Jt2: The Retirement Fund of the building trades in the Chicoutimi, Luc St-Jean ami Rohcrval regions is established for the sole purpose «>f provuling for the employees the benefit*, set out in divisions 11, 12 and 13 of this title.Section 43: The Retirement Fund shall consist of all monies allocated to it according to section 13 of this title, together with the earnings ami profits thereon, all investments made therewith, proceeds thereof and nil earnings and profits thereon.Investments from such fund shall comply with the requirements lai«l down by the Québec Pension Hoard.Division 11 Retirement benefits Section .'t.'f: Until otherwise determined, the amount «>f monthly normal retirement benefits payable to any employee the Social Security Commit tec's approval.The pension increase shall be equivalent tf the first monthly payment of any pension shall be the first day of the month following the month in which the employee becomes qualified for retirement pension benefits.The due date of the last monthly payment shall be the first day of the month in whi«-h the pensioner passes away.\\o pension payment shall be made f«>r that portion of the month in which he «lies, between the first ilay f his death.Section .',n: Contributions ma«le by or in the name of a retired employee iu respect of hours of work on or after the due «late of his first monthly pension instalment will neither increase the amount «»f pension payable t«> the retired employee nor increase his accumulated employee assessments.Section 50: No retirement pension benefit payable under this title may be attached or assigned.No portion of the Retirement Pmul shall become or be the property «>f any individual.No pension or other benefit payable hereunder shall become or be owing to any individual or become the properly of any individual until actually paid to him.Division 12 Rei-imbursement of accumulated employee assessments in case of death Section 51: In the event of the death of an employee or former employe*', there shall be payable a refund equal to his accumulated employee assessments less any pension payments received by the employee or former employee.Section 52: Any refund payable on the «leath of an employee or former employee shall be paid to the beneficiary upon making formal application therefor to the Social Security Committee.Nevertheless, the said Committee, in the absence of a formal application, shall notify the interested parties of their rights at the last known address of the deceased.However, the S
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.