Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 6 avril 1968, samedi 6 (no 14)
[" 100» ANNÉE VOL, 100 N° 14 2127 Gazette officielle à Québec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE Québec, samedi 6 avril 1968 Règlement» 1* Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la reine, Hotel du Gouvernement, Quebec.2\" Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3* Indiquer le nombre d'insertions.4\" Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées Eliisieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter i facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6° L'abonnement, la vente de documents, etc., ¦ont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.T La Gazelle officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire & midi, le mercredi, à moins 3uc ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime «'¦lui expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8* Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.0s Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Imprimeur de la reine avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Quebec, Saturday, April 6, 1968 Rules 1.Address all communications to the Queen's Printer, Parliament Buildings, Quebec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements arc payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to the Queen's Printer, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.6.Remittance must be mode by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach the Queen's Printer not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, the Queen's Printer reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties arc requested to notify the Queen's Printer before the second insertion, in order to avoid costly duplication.Publiée pab le Gouvernement de la Province / Published bt the Provincial Government L'lwprimmtr , avec un capital total de $40,000, divisé en 30,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 10,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 9, rue St-Louis, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous -secretaire de la province, Raymond Douville.24053-o 951-68 Bercourt inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de mars 1968, constituant en corporation: André Dufault, 1306, Montcalm, Saint-Joseph-de-Sorel, André Perron, 1830, Monseigneur Villeneuve, tous deux commerçants, et Bernard Vaillancourt, industriel, 4200, route Marie-Victorin, ces deux derniers de Tracy, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de transport, sous le nom de « Bercourt inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 4200, route Marie-Victorin, Tracy, district judiciaire de Richelieu.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 962-68 Bétons Asco inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de février 1968, constituant en corporation: Gélasc Courchesne, camionneur, Florence Bergeron, ménagère, épouse commune en biens dudit Gélase Courchesne, tous deux de Saint-Cyrille-de-Wendover, et Roméo I.amodie, journalier, 432, Surprenant, Drummondville, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce du ciment et de ses sous-produits, sous le nom de « Bétons Asco inc.», avec un capital total de $200,000, divisé en 40,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune et en 1,600 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Drummondville, district judiciaire de Drummond.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.240534» 821-68 Le Bifcoteck inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968, constituant en corporation: Marcel Beaudry, Rodrigue Farley, tous deux avocats, de Lucerne, et Louis Martineau, homme d'affaires, 39, Millar, (lull, pour les objets suivants: Exploiter des hotels, tavernes, auberges, restaurants, cafés, chalets et kiosques, sous le nom de « Le Bifcoteck inc.», avec un capital divisé en '.'\"ID actions ordinaires sans valeur nominale et en 3,200 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.2133 François Béland, 2560 de la Falaise, both of Sillery, and Simon Doyon, 1211 St-Cyrille west, Quebec, all three students, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Bejado inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 30,000 common shares of $1 each and 10,000 preferred shores of $1 each.The head office of the company is at 9 St-Louis St., Quebec, judicial district of Quebec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 951-68 Bercourt inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of March, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: André Dufault, 1306 Montcalm, Saint-Joseph-de-Sorel, André Perron, 1830 Monseigneur Villeneuve, both traders, and Bernard Vaillancourt, industrialist, 4200 Marie-Victorin Highway, the latter two of Tracy, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Bercourt inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each and 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 4200 Marie-Victorin Highway, Tracy, judicial district of Richelieu.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 962-68 Bétons Asco inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dote the 27th doy of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gélose Courchesne, truck driver, Florence Bergeron, housewife, wife common as to property of said Gélase Courchesne, both of Saint-Cyrille-de-Wendover, and Roméo Lomo-the, labourer, 432 Surprenant, Drummondville, for the following purposes: To manufacture and deal in cement and its by-products, under the name of \"Bétons Asco inc.\", with a total capital stock of $200,000.divided into 40,000 common shares of a nominal value of $1 each and into 1,600 preferred shores of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Drummondville, judicial district of Drummond.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 821-68 i., avec un capital total de 840.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 cliacunc et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-scerttaire de la province, Raymond Douville.24053 909-68 Black, housewife, wife separate as to property of the said Fred Essner, both of 890 Emerson Drive, Adolphe Taub, executive, and Ingeborg Zschottge, housewife, wife separate as to property of the said Adolphe Taub, the latter two of 4412 Notre-Dame, all four of Laval, for the following purposes: To manufacture, repair, lease and deal in sporting goods, sports clotliing, sporting equipment, hardware supplies, trailers and equipment, under the name of \"Caspo Rent-All Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of S10 each and 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Laval, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 909-68 Centre Laval Merchants Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de février 1968, constituant en corporation sans capital-actions: HaiTj Glasaman, 7015.Clover, Max Friedman, 5615 Eldridge, tous deux de Côte Saint-Luc, Jack Friedman, 199, Hurland, Hampstead, tous trois agents d'immeubles, Hélène Gaucher, comptable, épouse commune en biens de Fernand Rodrigue, 7055, De Lorimier, Montréal, et Leo Ruttcnberg, gérant.1092 Shevchenko, LaSalle, pour les objets suivants: Établir et maintenir, sans but lucratif, une association de marchands exerçant des affaires ensemble dans un centre commercial, sous le nom de « Centre Laval Merchants Association ».La valeur de la propriété immobilière que la corporation est en droit de posséder, n'excédera pas 8100.000.Le siège social de la corporation est à LaSalle, district judiciuirc de Montréal.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24053 878-68 Centre Laval Merchants Association Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of February, 1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Harry Glassman, 7015 Clover, Max Friedman, 5615 Eldridge.both of Côte Saint-Luc, Jack-Friedman, 199 Harland, Hampstead, all three realtors.Hélène Gaucher, accountant, wife common as to property of Fernand Rodrigue.7055 De Lorimier.Montreal, and Leo Ruttcnberg, manager, 1092 Shevchenko, LaSalle, for the following purposes: To establish and maintain a non-profit association of merchants carrying on business together in a Shopping Centre, under the name of \"Centre Laval Merchants Association\".The value of the immovables that the corporation is entitled to possess sliall not be in excess of 8100,000.The head office of the corporation is at LaSalle, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 878-68 Centre Psycho-pédagogique de Québec inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Thérèse Joncas, pédagogue, veuve d'André Ouellct, 435, Lcarmont, Québec, Maurice Meunier.860, St-Jcan-Bosco, et Jean-Charles Lessard, 2004, Hocquart, ces deux derniers psychologues, de Saintc-Foy, pour les objets suivants: Dispenser un enseignement spécialisé à des groupes d'enfants ou à des enfants individuellement qui ont des difficultés scolaires manifestées Car des problèmes d'apprentissage ou des perturbions affectives, sous le nom de < Centre Psycho-pédagogique de Québec inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 8100.000.Le siège social de la corporation est à Québec, district judiciaire de Québec.Centre Psycho-pédagogique de Québec inc.Notice is given that under Part HI of the Companies Act.letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without sliare capital: Thérèse Joncas, pedagogue, widow of André Oucllet.435 Lcarmont, Quebec, Maurice Meunier, 860 St-Jcan-Bosco, and Jean-Charles Lessard, 2004 Hocquart.the latter two psychologists of Saint Foy, for the following purposes: To dispense vocational training to groups of children or to children individually who have school difficulties manifested by apprenticeship problems or affective perturbations, under the name of \"Centre Psycho-pédagogique de Québec inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is 8100,000.The head office of the corporation is at Quebec, judicial district of Quebec.Le sous-secrâtaire de la province, Raymond Douville.24053-o 649-68 Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 649-68 2138 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100' année, n' H Le Centre sportif du 1er Rang inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Richard Ménard, employé d'usine, Pauline Lajoie, ménagère, fille majeure, tous deux de route rurale numéro 1, et André Lcdoux, inspecteur, 62, boulevard Rose-Marie, tous trois de Saintc-Cccile-de-Milton, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de « Le Centre sportif du 1er Rang inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de §25 000.Le siège social de la corporation est A Sainte-Cécile-de-Milton, district judiciaire de Bedford.Le sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.24053-o 894-68 Cha-Lem inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de février 1968, constituant en corporation: Fernand Charest, administrateur, Alice St-Martin, ménagère, épouse séparée de biens dudit Fernand Charest, tous deux de 712, Lasaicr, Saint-Jean, Jacques I.ci n aire, administrateur, et Nicole Boutin, ménagère, épouse séparée de biens dudit Jacques Lemairc, ces deux derniers de 245, Héroux, Iberville, pour les objets suivants: Exploiter des entreprises de camionnage, sous le nom de « Cha-Lem inc.», avec un capital total de 8100,000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est rue Aubry, Saint-Jean, district judiciaire d'Ibcrville.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 882-68 Chaussures Porto - Fino inc.Porto - Fino Shoes Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22c jour de février 1968, constituant en corporation: Louis (îoulet, ingénieur, 5655, De Gaulle, Charlcsbourg, Thomas Mainvillc, importateur, et Yvonne G.Mainville, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Thomas Mainvillc, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, ces deux derniers de 830, de la Colombière est, Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce et l'importation de toutes sortes d'articles et de produits de métal, bois, de matières plastiques, caoutchouc, cuir et textiles, sous le nom de « Chaussures Porto-Fino inc.\u2014 Porto-Fino Shoes Inc.».avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 840, de la Colombière est, Québec, district judiciaire de Quégec.Le Centre sportif du 1er Rang inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act.letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Richard Ménard, factory employee, Pauline Lajoic, housewife, spinster of the full age of majority, both of rural route number 1.and André Ledoux, inspector.62 Rose-Marie boulevard, all three of Sainte-Cécilc-de-Milton, for the following purposes: The organization of recreational activities, under the name of \"Le Centre sportif du 1er Rang inc.\".The amount to which are limited the immovables which may lie acquired and owned by the corporation is 825,000.The head office of the corporation is at Saintc-Cécilc-dc-Milton, judicial district of Bedford.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 894-68 Cha-Lem inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Fernand ('barest, administrator, Alice St-Martin, housewife, wife separate as to property of said Fernand Charest, both of 712 Lasnicr, Saint-Jean, Jacques Lemaire, administrator, and Nicole Boutin, housewife, wife separate as to property of said Jacques Lemairc, the latter two of 245 Héroux, Iberville, for the following purposes: To operate trucking businesses, under the name of \"Cha-Lem inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 500 common shares of 8100 each and into 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Aubry Street, Saint John's, judicial district of Iberville.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 882-68 Chaussures Porto - Fino inc.Porto - Fino Shoes Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Louis Goulct, engineer, 5655 De Gaulle, Charlcsbourg, Thomas Mainville, importer, and Yvonne G.Mainville, housewife, wife contractually separate as to property of said Thomas Mainville, and duly authorized by him for these presents, the latter two of 830 de la Colombièrc-east, Québec, for the following purposes: To deal in and import of all kinds of articles and products in metal, wood, plastic, rubber, leather and textile, under the name of \"Chaussures Porto-Fino inc.\u2014 Porto-Fino Shoes Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 840 de la Colombière-East, Quebec, judicial district of Quebec.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 827-68 Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 827-68 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.Ik 2139 Le Cheval de Bois Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de février 1968, constituant en corporation: Conrad Shatner, avocat, 4725, avenue Fulton, Montréal, Jo Ann Israel, secrétaire, célibataire, 3606, Le Boulevard, Westmount, et Melvin Kronish, étudiant, 5501, Adalbert, Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de « Le Cheval de Bois Itée », avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053 658-68 Chez Pierre & Carlo inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1968, constituant en corporation: Pierre Machard, mattre-d'hôtel, rue Desjardins, Carlo Zopeni, chef-cuisinier, 167A, rue Lesage, tous deux de Sainte-Adèle, et Alain Voizard, notaire, 266, Glengarry, Mont-Royal, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de « Chez Pierre & Carlo inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sainte-Adèle, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 945-68 Club Connaissance du Monde inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 12c jour de février 1968, constituant en corporation: André Trotier, avocat, 1074, Belmont, Claude Michel, homme d'affaires, 2260, Masson, tous deux de Sillery, et Paule Gauthier, avocate, fille majeure, 630, Père Marquette, Québec, pour les objets suivants: Préparer, éditer et vendre toutes sortes de matières imprimées concernant les divers pays et les voyages, sous le nom de « Club Connaissance du Monde inc.», avec un capital total de 510,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 100, d'You-ville, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-secrétaire de la produce, Raymond Douville.24053-o 797-58 Clem inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de février 1968, constituant en corporation: Michel Lalande, 4604, Gamier, Laurier Gagnon, 2408, De Mai-sonneuve, tous deux vendeurs, et Paul Clément, marchand, 7290, Sagard, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Le Cheval de Bois Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Conrad Shatner, attorney, 4725 Fulton Avenue, Montreal, Jo Ann Israel, secretary, spinster, 3606 The Boulevard, Westmount, and Melvin Kronish, student, 5501 Adalbert, Côte Saint-Luc, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Le Cheval de Bois Itée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 658-68 Chez Pierre & Carlo inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Machard, mattre-d'hôtel, Desjardins St., Carlo Zopeni, head chef, 167A Lesage St., both of Sainte-Adèle, and Alain Voizard, notary, 266 Glengarry, Mount-Royal, for the following purposes: To operate hotels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Chez Pierre & Carlo inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of $10 each and 300 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Sainte-Adèle, judicial district of Terrebonne.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 945-68 Club Connaissance du Monde inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 12th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: André Trotier, advocate, 1074 Belmont, Claude Michel, businessman, 2260 Masson, both of Sillery, and Paule Gauthier, advocate, spinster of the full age of majority.630 Père Marquette, Quebec, for the following purposes: To prepare, publish and sell all types of printed matter concerning various countries and travel, under the name of \"Club Connaissance du Monde inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 100 d'You ville, Quebec, judicial district of Quebec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 797-68 Clem Inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Michel Lalande, 4604 Gamier, Laurier Gagnon, 2408 De Maisonneuve, both salesman, and Paul Clément, merchant.7290 Sagard, all three of Montreal, for the following purposes: 2140 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, G avril 1968, 100' aimée, n° H Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de vêtements, sous le nom de « Clem inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 616-G8 Club nautique de Sillcry Sillcry Nautical Club Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 12c jour de mars 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-Pierre Arsenault, représentant, 2036, avenue Muir, app.5, Saintc-Foy, Jcan-Claudc Hamcl, évaluateur, 1530, Du Verger, et Léo Charland, employé municipal, 1270, De Villars, ces deux derniers de Sillcry, pour les objets suivants: Former, établir et exploiter un club nautique, sous le nom de « Club nautique de Sillery \u2014 Sillcry Nautical Club ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $500,000.Le siège social de la corporation est à Sillcry, district judiciaire de Québec.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 1128-68 Club sportif Cowansville inc.Sportsmen Club Cowansville Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour de février 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Arthur Christian Todd, courtier en immeuble, 521 Beaumont, Roland Côté, agent d'assurances, 452, Belle, Fred Barber, agent des achats, 316, Davignon, Jean-Pierre Mallette, gérant du personnel, 138, Yamaska, et Paul-Emile Matton, gérant de quilles, 221, Bernard, tous cinq de Cowansville, pour les objets suivants: Établir, entretenir et diriger un club athlétique, sous le nom de « Club sportif Cowansville inc.\u2014 Sportsmen Club Cowansville Inc.».Le montant auquel se limite la valeur des biens immobiliers que peut acquérir ou posséder la corporation est de $250,000.Le siège social de la corporation est à Cowansville, district judiciaire de Bedford.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053 484-68 Compagnie de placement Sauvcmont inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de février 1968, constituant en corporation: Roland Robillard, vendeur, Roger Trudeau, ajusteur d'assurances, tous deux de Saint-Sauvcur-dcs-Monts, Claude Lalonde, pharmacien, 607, Carré Dumay, Sainte-Thérèse, Florian Brissette.comptable agréé, 1585, boulevard d'Autcuil, André Turcotte, gérant de crédit, 140,5c avenue, tous deux de Laval, Raymond Tougas, épicier, 12059.Daigle, Armand Trudeau, surveillant, 6801, Iberville, To manufacture and deal in all kinds of garments, under the name of \"Clem inc.\", with a total capital sock of 840,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 616-68 Club nautique de Sillcry Sillery Nautical Club Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of March, 1938, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without shore capital: Jean-Pierre Arsenault.representative, 2036 Muir Ave., Apt.5, St.Foy, Jean-Claude Hamcl, valuator, 1530 Du Verger, and Léo Charland, municipal employee, 1270 De Villars, the latter two of Sillery, for the following purposes: To form, establish and operate a nautical club, under the name of \"Club nautique de Sillery \u2014 Sillery Nautical Club\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $503.000.The head office of the corporation is at Sillery, judicial district of Quebec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 1128-63 Club sportif Cowansville inc.Sportsmen Club Cowansville Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Arthur Christian Told, real estate broker, 521 Beaumont, Rohm I Côté, insurance agent, 452 Bell, Fred Barber, purchasing agent, 316 Davignon, Jean-Pierre Mallette, personnel manager, 138 Yamasko, and Paul-Emile Matton, bowling manager, 221 Bernand, all five of Cowansville, for the following purposes: To establish, maintain and conduct an athletic club, under the nome of \"Club sportif Cowansville inc.\u2014 Sportsmen Club Cowansville Inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may hold or own is to be limited, is $250,000.The head office of the corporation is at Cowansville, judicial district of Bedford.Raymond Douville, Assistant Secretary of tlu Province.24053-o 484-68 Compagnie de placement Sauvemont inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roland Robillard, salesman, Roger Trudeau, insurance adjuster, both of Saint-Sauveur-des-Monts, Claude Lalondc, pharmacist, 607 Dumay Square, Sainte-Thérèse, Florian Brissettc, chartered accountant.1585 d'Auteuil Boulevard, André Turcotte, credit manager, 140, 5lh Avenue, both of Laval, Raymond Tougas, grocer, 12059 Daigle, Armand Trudeau, superintendent, 6801 Iberville, Bernard Lapierre, police- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.U 2141 Bernard Lapierrc, policier, 6975, 13e avenue, tous trois de Montréal, Jean Préville, ferblantier, 166, Bellerive, Rosemère, et Leopold Bcaulieu, inspecteur, 3981, Forest, Montréal-Nord, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placement, sous le nom de < Compagnie de placement Sauve-mont inc.», avec un capital total de $50,000, divisé en 3.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social- de la compagnie est à Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 799-68 La Compagnie des Attractions de Montréal Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 7c jour de février 1968, constituant en corporation: Alan Z.Golden, avocat.625.Milton, Anne Scaroni, 3484, Aylmer, et Helen Marshall.5339, Côte St-Luc, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce qui consiste A procurer des divertissements au public, et exploiter des restaurants, sous le nom de « La Compagnie des Attractions de Montréal Itée», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053 549-68 Les Constructions Grenoble inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de mars 1968, constituant en corporation: Roland Poulin, entrepreneur, Pierrette Cormier, ménagère, fille majeure, tous deux de 408, Desmarchais, et Bernard Rodrigue, comptable, 397, Brunit, tous trois de Jacques-Cartier, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Les Constructions Grenoble inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 408, Des-marchais, Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.-M053-o 437-68 Continental Air Freight Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de février 1968, constituant en corporation: David Clwyd Griffiths, gérant, Margaret Blodwen Griffiths, ménagère, veuve, tous deux de 805, Lakcshore Drive, «pp.5, Dorval, Gladys MacLeod, secrétaire légale, célibataire, 2100, Tupper, app.102, Montréal, et Kathleen Mulhern, commis, célibataire, 2731, ¦»\u2022 T.rue Rothwell, Lachine, pour les objets suivants: man, 6975, 13th Avenue, all thereof Montreal, Jean Prévillc, tinsmith, 166 Bellerive, Rosemère, and Leopold Bcaulieu, inspector, 3981 Forest, Montreal North, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Compagnie de placement Sauvemont inc.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 3.000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred sliares of $10 each.The head office of the company is at Laval, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 799-68 La Compagnie des Attractions de Montréal Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Alan Z.Golden, advocate, 625 Milton, Anne Scaroni.3484 Aylmer, and Helen Marshall, 5339 Côte St-Luc, the latter two secretaries, filles majeures, all three of Montreal, for the following purposes: To carry or.the business of furnishing amusement to the public and to operate restaurants, under the name of \"La Compagnie des Attractions de Montréal Itée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 549-68 Les Constructions Grenoble inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of March, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roland Poulin, contractor, Pierrette Cormier, housewife, spinster of the full age of majority, both of 408 Desmarchais, and Bernard Rodrigue, accountant, 397 Brault, all three of Joc-ques-Cortier, for the following purposes: To carry on business as general building constructors and contractors, under the name pf \"Les Constructions Grenoble inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at 408 Des-marchais, Jacques-Cartier, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 437-68 Continental Air Freight Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: David Clwyd Griffiths, manager, Margaret Blodwen Griffiths, housewife, widow, both of 805 Lakeshore Drive, Apt.5, Dorval, Gladys MacLeod, legal secretary, spinster, 2100 Tupper, Apt.102, Montreal, and Kathleen Mulhern, clerk, spinster, 2731 J.T.Rothwell Street, Lachine, for the following purposes: 2142 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 19G8, 100' année, n\" U Agir en qualité rie courtiers, expéditeurs, importateurs et exportateurs de fret et marchandises générales par air, terre et mer, sous le nom de « Continental Air Freight Ltd.», avec un capital total de 840,090, divisé en 1,033 actions ordinaires d'une \\ al m i au pair de 810 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Dorval, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la \"province, Raymond Douville.24053 620-68 To act as brokers, forwarders, importers and exporters of freight and general merchandise by air, land and sea, under the name of \"Continental Air Freight Ltd.\", with a total capital stock of $10,033, divided into 1,030 common shares of the par value of $10 each and 300 preferred shares of the par value of $103 each.The head office of the company is at Dorval, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 620-68 Cosmétiques « Gai de Paris » inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 21c jour de février 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Gerald Gordon Freed, avocat, 1225, Sussex, app.606, Dcrricc Louise Leacock, 4455, Coolbrook, tous deux de Montréal, et Patricia Alwyn Borlace, 1812, Lac Brise, Deux-Montagnes, ces deux dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: Faire commerce d'un salon de beauté et exercer le commerce de cosmétiques de toutes sortes et descriptions, sous le nom de « Cosmétiques « Gai de Paris » inc.», avec un capital total de 840,000, divise en 1,030 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3.900 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la corporation est 2004, chemin Chambly, Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal.Le sous-sccrélairc de la province, Raymond Douville.24053 SS0-GS Cosmétiques \"Gai de Paris\" inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 21st day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gerald Gordon Freed, advocate, 1225 Sussex, Apt.606, Derricc Louise Lcacock, 4455 Coolbrook, both of Montreal, and Patricia Alwyn Borlace, 1812 Lake Breeze, Deux-Mon-tagncs, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To carry on business as operators of a beauty salon and to manufacture and deal in cosmetics of every nature and description, under the name of \"Cosmétiques \"Gai de Paris\" inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 1.000 common shares of a par value of $1 each and 3,900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at 2004 Chambly Road, Jacqucs-Carticr, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 880-68 La Coupole des Gastronomes inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de février 1968, constituant en corporation: Madeleine Pesant, secrétaire, fille majeure, 1684, Camille-Paquet, app.2, Montréal, John R.Laffoley, 201, Kinders-lcy, Mont-Royal, et Jean-Guy Riopcl, 641, Stuart, Outremont, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: Exploiter un ou des hôtels, motels, restaurants, cafés, chalets et kiosques, sous le nom de * La Coupole des Gastronomes inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 2.000 actions ordinaires de 810 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Windsor, district judiciaire de Saint-François.Le sous secrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 813-68 DBM Industries Limited Les Industries DBM limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8c jour de février 1968, constituant en corporation: Clifford (îcorge Meek, Montréal, Guy Ambrose Miller, Saint-Bruno-dc-Montarville, et Colin Richard Chish-olm, LaSalle, tous trois comptables, pour les objets suivants: La Coupole des Gastronomes inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 20th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Madeleine Pesant, secretary, spinster of the full age of majority.1681.Camille-Paquet, Apt.2, Montreal, John R.Laffoley, 204 Kinderslcy, Mount-Royal, and Jean-Guy Riopel, 641 Stuart, Outrcmont, the latter two advocates, for the following purposes: To operate hotels, motels, restaurants, cafés, cottages and kiosks, under the name of \"La Coupole des Gastronomes inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 2.000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Windsor, judicial district of Saint Francis.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.24053 813-68 DBM Industries Limited Les Industries DBM limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 8th day of February.1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Clifford (îcorge Meek, Montreal, (iuy Ambrose Miller, Saint-Brur.o-de-Montar-ville, and Colin Richard Chisholm, LaSalle, all three accountants, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April G, 19G8, Vol.100, No.U 2143 Fabriquer toutes sortes de machines, machinerie, appareils, outils, instruments, équipements, accessoires, pièces constituantes, fournitures, raccordements et matériaux connexes et en faire le commerce, sous le nom de « DBM Industries Limited \u2014 Les Industries DBM limitée», avec 110 capital total de $60.000.divisé en 40.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées d'une valeur BU pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.LM053 508-68 To manufacture and deal in all kinds of machines, machinery, apparatus, tools, implements, equipment, accessories, components, parts, supplies, attachments and materials, under the name of \"DBM Industries Limited \u2014 Les Industries DBM limitée\", with a total capital stock of $60.000, divided into 40,000 common shares of a par value of $1 each and 20,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Produce.24053-o 508-68 B.D'Amours construction Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de février 1968.constituant en corporation: Serge Bourque, avocat.(ïertrude L'Heureux, secrétaire, veuve de Guy Murray, et Carole Hébert, secrétaire, fille majeure, tous trois de 1155, Dorchester ouest, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom île « B.D'Amours construction Itée », avec un capital total de $40.000.divisé en 1.500 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 clutcune et en 250 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie 5152, rue Delorimier, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la produce, Raymond Douville.24053-o 871-68 R.L.Dawes Equipment Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de février 1968, constituant en corporation: Samuel II.Shriar 2445, Yaladc, Saint-Laurent, Harvey Cooper-stone, 1448, Beverley Crescent, tous deux avocats, .lovitte Dmuchalsky, 581.Ladouceur, tous deux ¦le Laval, et Aline Bcaulieu, 3801, Cavendish, Montréal, ces deux dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: Acheter, vendre, louer des équipements de construction, neufs et usagés et de la machinerie de toutes sortes, en faire le commerce, sous le nom de « R.L.Dawes Equipment Inc.», avec un capital total de $40.000.divisé en 10.000 actions ordinaires de $1 cliacune et 30,000 actions privilégiées de $1 cltacunc.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.J4053 656-68 L.Paul Desbiens Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 26c jour de février 1968, constituant en corporation: I .en l'a ni Dcshicns, commerçant, Brigitte de Santis, ménagère, épouse contractuellemcnt séparée de biens audit Léon- B.D'Amours construction Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, hearing date the 22th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Serge Bourque, advocate, Gertrude L'Heureux, secretary, widow of Guy Murray, and Carole Hébert, secretary, spinster of the full age of majority, all three of 1155 Dorchester West, Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders and general contractors, under the name of \"B.D'Amours construction liée\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1,500 common shares with a nominal value of $10 each, and 250 preferred shares with a nominal value de $100 each.The head office of the company is at 5152 Delorimier street, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 871-68 R.L.Dawes Equipment Inc.Notice is given that under Port I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Samuel H.Shriar, 2445 Valade, Saint-Laurent.Harvey Cooperstone, 1448 Beverley Crescent, both lawyers, Jovitte Dmuclialsky, 581 Ladouceur, both of Laval, and Aline Beau-lieu, 3801 Cavendish, Montreal, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To buy, sell, rent and otherwise deal in new and used construction equipment and machinery of all kinds, under the name of \"R.L.Dawes Equipment Inc.\", with a total capital stock, of $40.000.divided into 10.000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Pronnee.24053-o 656-68 !.Paul Desbiens Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Leon-Paul Dcsbiens, trader, Brigitte de Santis.housewife, wife contractually separate as to property of the said Léon-Paul 2144 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 19GS, 100' année, n° 1A Paul Desbiens, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de 489, De Sales, Chicoutimi, et Gaétanc Grenon, secrétaire, fille majeure.1940, Roussel, Chicoutimi-Nord, pour les objets suivants: Paire affaires comme compagnie de placement et de portefeuille (holding), sous le nom de « L.Paul Desbiens Itée », avec un capital total de 8500.000.divisé en GO actions ordinaires d'une valeur nominale de 810 chacune, 1,000 actions privilégiées classe « A » d'une valeur nominale de 810 chacune et en 4.894 actions privilégiées classe « B » d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Chicouti-mi, district judiciaire de Chicoutimi.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 5299-67 Dessin Deko Itée Dcko Design Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour de février 1968, constituant en corporation: Murray B.Spiegel, avocat, 63, chemin Banstead, Montréal-ouest, Franchie Végiard, 3465, Hutchison, Montréal, et Jovitte Dmuchalsky, 581, Ladouceur, Laval, ces deux dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: Importer, exporter, acheter, vendre, louer des fleurs, plantes et arbres naturels ou artificiels en général, en faire le commerce, sous le nom de « Dessin Deko Itée \u2014 Deko Design Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053 610-68 Desbiens, and duly authorized by him for these presents, both of 489 De Sales, Chicoutimi, and Gaétanc Grenon, secretary, spinster of the full age of majority, 1940 Roussel, Chicoutimi-North, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"L.Paul Desbiens Itée\", with a total capital stock of $500.000, divided into 60 common shares of a nominal value of $10 each, 1,000 preferred class \"A\" shares of a nominal value of $10 each and 4.894 preferred class \"B\" shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 5299-67 Dessin Deko Itée Deko Design Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Murray B.Spiegel, advocate, 63 Banstead Road, Montreal West, Francine Végiard, 3465 Hutchison, Montreal, and Jovitte Dmuchalsky, 581 Ladouceur, Laval, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To import, export, buy, sell, rent and generally deal with real and artificial flowers, plants and trees, under the name of \"Dessin Deko Itée \u2014 Deko Design Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10.000 common shares of $1 each and 30,000 preferred sliares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 610-68 Le Développement Immobilier de Sherbrooke inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour de décembre 1967, constituant en corporation: Paul Chevalier, Gérald Beaudry, Patrice Gauthier, Biaise Drapeau, Gaston Masson, Jean Belle Isle, Jean-Denis Dufresne, Toussaint Bouchard, Fernand Tan-guay, Jacques Bourquc, Jean Thibodeau, Jean Darche, Jean-Pierre Tremblay, Alexandre Mi-gnault, Léo Langis, Louis Hébert, Jacques Beaudry, Yvan Blouin et Alexandre Kindy, tous médecins, de Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, sous le nom de « Le Développement Immobilier de Sherbrooke inc.», avec un capital total de $200,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 280, rue King est, Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le Développement Immobilier de Sherbrooke inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of December, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul Chevalier, Gerald Beaudry, Patrice Gauthier, Blaise Drapeau, Gaston Mas-son, Jean Belle Isle, Jean-Denis Dufresne, Toussaint Bouchard, Fernand Tanguay, Jacques Bourque, Jean Thibodeau, Jean Darche, Jean-Pierre Tremblay, Alexandre Mignault, Léo Langis, Louis Hébert, Jacques Beaudry, Yvan Blouin, and Alexandre Kindy, all physicians, of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business as real estate company, under the name of \"Le Développement Immobilier de Sherbrooke inc.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 2,000 common shares of $100 each.The head office of the company is at 280 King street East, Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Le sous secrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 109-68 Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 109-68 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Fol.100, No.H 2145 Développement du Lac Manon inc.Développement du Lac Manon inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres palcntcs, en date du 23e jour de février 1968, constituant en corporation: Guy-P.Genest, avocat, 3152, Fendait, Paul Chevalier, étudiant, 5291, McKenna, tous deux de Montréal, et (ieorgcs-Yvon Gouin, avocat, 790, Davaar, Outrcmont, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Développement du Lac Manon inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de $5 chacune et en 3,900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Sauveur-dcs-Monts, district judiciaire de Terre-bonne.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 783-68 Don nan Cartage Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de février 1968, constituant en corporation: Gisèle Tourville, 3261, Forest Hilt, Gilbert Baron, 5154, Jeanne-Mance, toutes deux secrétaires, célibataires de Montréal, et Adrien-R.Paqucttc, avocat, 212, liloomfield, Outrcmont, pour les objets suivants: Kxcrcer un commercede camionnagect de transport, sous le nom de « Donnan Cartage Inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $10 chacune et 500 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 9945, l'ark George, Montréal-N'ord, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053 612-68 Ragle Door Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le licutcnant-gmvcrncur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de mars 1968, constituant en corporation: George I.Daughters, mécanicien, 4482, Rolland, Pierrcfonds, Dawne Heath, secrétaire, célibataire, 2270, Mautha, Saint-Laurent, et Cornelius Mofford, chef, 2331, Grand Boulevard, Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce de constructeurs et entrepreneurs et faire le commerce de matériaux de construction de toutes sortes, sous le nom de « Eagle Door Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10.000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 5871, avenue Victoria, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053 937-68 Elite Sportswear Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour de février 1968, Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Guy-P.Genest, advocate, 3152 Kendall, Paul Chevalier, student, 5291 McKenna, both of Montreal, and Georges-Yvon Gouin, advocate, 790 Davaar, Outremont, for the following purposes: To carry on business as a real estate and building company, under the name of \"Développement du Lac Manon inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $5 each and 3,900 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Saint-Sauveur-des-Monts, judicial district of Terrebonne.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 783-68 Donnan Cartage Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of February, 1968, have ben issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gisèle Tourville, 3261 Forest Hill, Gilbertc Baron, 5154 Jcanne-Mancc, both secretaries, spinsters, of Montreal, and Adrien-R.Paquette, lawyer, 212 Bloomficld, Outremont, for the following purposes: To carry on a trucking and cartage business, under the name of \"Donnan Cartage Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 5,000 common shares of $10 each and 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 9945 Park George, Montreal North, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 612-68 Eagle Door Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 1st day of March.1968.Iiavc been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: (îcorge I.Daughters, mechanic, 4482 Rolland, Pierrefonds, Dawne Heath, secretary, spinster, 2270 Mantlia, Saint-Laurent, and Cornelius Mofford, chef, 2331 Grand Boulevard, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of builders and contractors and to deal in building materials of all kinds, under the name of \"Eagle Door Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred sliarcs of $10 each.The head office of the company is at 5871 Victoria Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 937-68 Elite Sportswear Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, 214G GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 19G8, 100' année, n° IL constituant en corporation: Arthur Yanofsky, 5872.Fcrncroft.Hampstead, Irving Narvey, 2400, avenue Gold, Saint-Laurent, tous deux avocats.Sheila Raymond, 89, Roxton Crescent, Montréal-Ouest, et Delphine Matthew, 3455, rue Ayhner, Montréal, ces deux dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de vêtements et d'accessoires vestimentaires de toutes sortes, sous le nom de « Flite Sportswear Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est A Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053 864-68 IiCB Entreprises Éclair inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de février 1968, constituant en corporation: Paul Manchette, commerçant, Claire Daigle, ménagère, épouse dudit Paul Manchette, tous deux de route rurale numéro 5, et André Horion, commis, 24, 10e avenue sud, tous trois de Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire affaires comme marchands généraux, sous le nom de « Les Entreprises Eclair inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est route rurale numéro 5, Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 814-68 Entreprises Galcx Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968, constituant en corporation: Jean Gagnon, 715, Closse, Saint-Lambert, Guy Dupré, 5480, Lavoie Montréal, tous deux avocats, et Cécile Paumier, secrétaire, épouse de Georges Paumier, 510, 27e avenue, Pointe-aux-Trembles, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de placement, sous le nom de « Entreprises Golex liée», avec un capital total de $400,000, divisé en 7,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est A Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 572-68 incorporating: Arthur Yanofsky, 5872 Fcrncroft, Hampstead.Irving N'arvey, 2400 Gold Avenue, Saint-Laurent, both advocates.Sheila Raymond.89 Roxton Crescent, Montreal West, and Delphine Matthew, 3455 Aylmer Street, Montreal, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Elite Sportswear Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1.000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 8G4-68 Les Entreprises Éclair inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul Manchette, trader, Claire Daigle, housewife, wife of the said Paul Blon-chette, both of rural route number 5, and André Horion, clerk, 24, 10th Ave.South, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business as general merchants, under the name of \"Les Entreprises Éclair inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at ruraf route number 5, Sherbrooke, judicial district ol Saint Francis.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 814-68 Entreprises Galex Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean Gagnon, 715 (Tossc Saint-Lambert, Guy Dupré, 5480 Lavoie, Montréal, both advocates and Cécile Paumier, secretary, wife of (îeorges Paumier, 510, 27th Avenue, Pointe-aux-Trembles, for the following purposes: To carry on business as a real estate and investment company, under the name of \"Entreprises Galex Itée\", with a total capital stock of $400,000, divided into 7,503 common shares of $10 each and 3,250 preferred shares of $100 each.The head ollicc of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of tlie Province.24053 572-68 Entreprises Lucien Brouillette, Itée Entreprises Lucien Brouillette, Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968, constituant en corporation: Lucien Brouillette, pharmacien, Ginette Provost, ménagère, épouse dudit Lucien Brouillette, tous deux de 10640, Parthenais, Montréal, et Antoni Valenti, courtier en assurance, 1765, Radisson, Laval, pour les objets suivants: Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Lucien Brouillette, pharmacist, Ginette Provost, housewife, wife of the said Lucien Brouillette, both of 10640 Parthenais, Montreal, and Antoni Valenti, insurance broker, 1765 Radisson, Laval, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.Il 2147 Faire le commerce de tous produits, articles et marchandises et faire affaires comme compagnie de portefeuille, de placement et de gestion, sous le nom de « Entreprises Lucien Brouillette, Itée », avec un capital total de $200,000, divisé en 20 actions ordinaires de $10 chacune, 19,972 actions privilégiées classe « A » de $10 chacune et en 80 actions privilégiées classe « B » de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 3108, 40e rue, Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 728-68 Entreprises Mont Sub inc.Mont Sub Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968, constituant en corporation: André Valiquelte, 3310.Beauséjour, J.-V.-Bernard Boudrias, 1307, Brochu, et (iuy-Frcdéric Gervais, 1195, Quenne-ville, tous trois avocats, de Saint-Laurent, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits, articles et marcliandises de toutes sortes, sous le nom de « Entreprises Mont Sub inc.\u2014 Mont Sub Enterprises Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 370 actions privilégiées de 8100 chacune.I.e siège social de la compagnie est 9207, rue Foucher, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous sécréta ire de la province, Raymond Douville.21053-o 667-68 Les Équipements Grenier inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968, constituant en corporation: Jean-Charles Grenier, 1005, Gervais, Lucien Grenier, 1055, Ladouceur, tous deux vendeurs, et Robert Boisjoli, mécanicien, 1554, Piette, tous trois de Jolictte, pour les objets suivants: Faire le commerce de meubles, équipements et accessoires servant aux boucheries, épiceries, boulangeries de même que tous les articles se rapportant au mobilier de bureau, sous le nom \u2022 le « Les Équipements Grenier inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Joliette, district judiciaire de Joliette.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.-M053-o 824-68 Espérance investissement inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de février 1968, consUtuant en corporation: Pierre Zech, éditeur, Marie-Hélène Patigny, ménagère, épouse séparée de biens dudit Pierre Zech, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de 78, -Mire, Espérance, France, et Jean Legast, industriel, 10, chemin Bras de Fer, Soignies, Belgique, pour les objets suivants: To deal in all products, articles and merchandise, and to carry on business as a holding, investment and management company, under the name of \"Entreprises Lucien Brouillette, Itée\", with a total capital stock of $200,000, divided into 20 common shares of $10 each, 19,972 preferred class \"A\" shares of $10 each and 80 preferred class \"B\" shares of $1 each.The head office of the company is at 3108,40th St., Saint-Michel, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 728-68 Entreprises Mont Sub inc.Mont Sub Enterprises Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: André Valiquette, 3340 Beauséjour, J.-V.-Bernard Boudrias, 1307 Brochu, and Guy-Frederic Gervais, 1195 Qucnneville, all three advocates, of Saint-Laurent, for the following purposes: To deal in products, articles and merchandise of all kinds, under the name of \"Entreprises Mont Sub inc.\u2014 Mont Sub Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $1 each and 370 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 9270 Foucher Street, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 667-68 Les Équipements Grenier inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, have been issued by the Ljeutcnant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Charles Grenier, 1005 Gervais, Lucien Grenier, 1055 Ladouceur, both salesman, and Robert Boisjoli, mechanic, 1554 Pictte, all three of Joliette, for the following purposes: To carry on business dealing in furniture, equipment and accessories used in butcher shops, grocery stores and bakeries and in all articles related to office furnishings, under the name of \"Les Équipements Grenier inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Jolictte, judicial district of Joliette.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 824-68 Espérance investissement inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Zech, editor, Marie-Hélène Patigny, housewife, wife separate as to property of said Pierre Zech, and duly authorized by him for the presents, both of 78 Mere, Espérance, France, and Jean Legast, industrialist, 10 Bras de Fer Road, Soignies, Belgique, for the following purposes: 21-18 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 19GS, 100' année, n\" H Faire affaires comme compagnie de placement, sous le nom de « Espérance investissement inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,600 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 5504, avenue Verdun, Verdun, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 766-68 To carry on business as an investment company, under the name of \"Espérance investissement inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $10 each and into 3,600 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 5504 Verdun Avenue, Verdun, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 766-68 Europe Plastic Moulds, Tools & Dies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de février 1968, constituant en corporation: Alberto Alvarez, 1804, ouest, Stc-C'atherine, Joaquim Lopes.4721, Barclay, tous deux machinistes, et Manuel Nicolau.garçon de table, 3489, Hôtel de Ville, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de moules en plastique, outils et matrices et de tous autres articles fabriquées, en tout ou en partie, de plastique ou de tout autre matière semblable, sous le nom de « Europe Plastic Moulds.Tools & Dies Ltd.», avec un capital total de $40,000.divisé en 30,000 actions ordinaires de $1 chacune et 10.000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire de la prorince, Raymond Douville.24053 621-68 F.G.L.Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de février 1968, constituant en corporation: Joseph R.Lynch, gérant de construction, 5840, Vilcourt, Brossard, Luigi GracefTa, surintendant de la construction, 11309, Jcan-Mcunicr, Montréal-Xord, et Gary Moscowitz, avocat, 260, St-Aubin, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de portefeuille, sous le nom de « F.G.L.Holdings Inc.», avec un capital total île $40.000.divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 11309.Jean-Meunier, Montréal-nord, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053 833-68 F.P.Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de février 1968, constituant en corporation: Jack B.Bobrove, 5615.Cork, Côte Saint-Luc.Edward H.Bem-feld, tous deux avocats, Marc Bernfeld, avocat et conseil en Loi de la reine, tous deux de 1117, ouest, rue Ste-Catherine, et John R.Howard, secrétaire, 1420, rue Towers, app.703, ces trois derniers de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « F.P.Construction Inc.», avec un capital total de Europe Plastic Moulds, Tools & Dies Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 9th day of February, 1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: All>erto Alvarez.1804 St.Catherine West, Joaquim Lopes.4721 Barclay, both machinists, ami Manuel Nicolau, waiter.3489 City Hall, all three of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in plastic moulds, tools and dies, and all other articles made in whole or in part from plastic or any similar material, under the name of \"Europe Plastic Moulds.Tools & Dies Ltd.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 30.000 common shares of $1 each and 10.000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dor ville.Assistant Secretary of the Province.24053-o 621-68 F.G.L.Holdings Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 21st day of February.1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Joseph R.Lynch, construction manager, 5840 Vilcourt, Brossurd.Luigi Graccffa, construction superintendent.11309 Jean-Mcu-nicr, Montreal North, and Gary Moscowitz, advocate, 260 St.Aubin.Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"F.G.L.Holdings Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 11309 Jean-Meunier, Montreal North, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 833-68 F.P.Construction Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 22nd day of February, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jack B.Bobrove, 5615 Cork.Côte Saint-Luc.Edward H.Bernfeld.Iioth advocates, Mac Bernfeld, advocate and Queen's Counsel, both of 1117 St.Catherine Street West, anil John R.Howard, secretary, 1420 Towers Street, Apt.703, the latter three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"F.P.Construction Inc.\", with a total capital stock QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.April 6, 1968, Vol.100, No.U 2149 $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 39,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est h Montréal, district judiciaire de Montréal, Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24053 803-68 Ferme La Poule Blanche, ltéc Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968.constituant en corporation: Paul-Émile Lanoie, industriel, Denise Plouffc, secrétaire, épouse dudit Paul-Émile Lanoie, et Jean-Guy Lanoie, cultivateur, tous trois de Upton, pour les objets suivants: Faire le commerce des oeufs frais ou congelés, sous le nom de « Ferme La Poule Blanche, Itée.» avec un capital total de 8100.000, divisé en 1.000 actions ordinaires de S10 chacune et en 9,000 actions privilégiées de $10 chacune.Ia: siège social de la compagnie est à Upton, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24053-o 527-68 Fermes Monts Cascades Itée Cascades Mountains Farming Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour de janvier 1968, constituant en corporation: Arthur Brown, fermier, Edward Omholt-Jcnscn, écrivain, tous ileux de Kirds Ferry, et Milton Cross, vendeur de bois, route rurale No 3, Wakefield, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses spécialités, l'exploitation agricole et de culture, sous le nom de « Fermes Monts Cascades Itée \u2014 Cascades Mountains Farming Ltd.*, avec un capital-actions divisé en 2.150 actions ordinaires sans valeur au pair et 6,900 actions privilégiées de $10 chacune.!.\u2022\u2022 siège social de la compagnie est à Hull, district judiciaire de Hull.Le sous-seerftaire de la province.Raymond Douville.24053 4944-67 Fiorito assurance limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour de février 1968 constituant en corporation: Antoine Fiorito, industriel, 934, boulevard Saraguay, Pierrefonds, Pierre Séguin, souscripteur d'assurances, 7602, Verdier, Saint-Léonard, et Bernard René, comptable, 3655, Papineau, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers et agents en assurance, sous le nom de « Fiorito assurance limitée », avec un capital total de $75,000, divisé en 4.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 3,500 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24053-o 898-68 of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each and 39,000 preferred sliares of a par value of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 803-68 Ferme La Poule Blanche, Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, , incorporating: Paul-Ëmile Lanoie, industrialist.Denise Plouffc, secretary, wife of the said Paul-Émile Lanoie, and Jean-Guy Lanoie, farmer, all three of Upton, for the following purposes: To carry on business dealing in fresh or frozen eggs, under the name of \"Ferme La Poule Blanche, Itée\", with a total capital stock of $100.000.divided into 1,000 common shares of $10 each and 9,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Upton, judicial district of Saint Hyacinthe.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 527-68 Fermes Monts Cascades Itée Cascades Mountains Farming Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of January.1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Arthur Brown, farmer, Edward Omholt-Jensen, writer, both of Kirks Ferry, and Milton Cross, lumber dealer.Rural Route No.3, Wakefield, for the following purposes: To carry on in all its branches the general business of farming and agriculture, under the name of \"Fermes Monts Cascades ltéc \u2014 Cascades Mountains Farming Ltd.\", with a capital stock divided into 2,150 common shares without par value and 6.900 preferred shares of $10 each The head office of the company is at Hull, partie Ouest, judicial district of Hull.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 4944-67 Fiorito assurance limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 26th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Antoine Fiorito, industrialist, 934 Saraguay Boulevard, Pierrefonds.Pierre Séguin, insurance underwriter.7602 Verdier, Saint-Léonard, and Bernard René, accountant, 3655 Papineau, Montreal, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers and agents, under the name of \"Fiorito assurance limitée\", with a total capital of $75.000, divided into 4,000 common shares of a nominal value of $10 each and 3,500 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.24053 898-68 2150 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100' année, n' H Fondation Populaire des bourses d'études inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de février 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Michel Tanguay, homme d'affaires, 1101, Parc Lafontaine, Montréal, Jacques Rolland, homme d'affaires, et Denise Archambault, ménagère, épouse dudit Jacques Rolland, ces deux derniers de 49, Ste-Rosc, Laval, pour les objets suivants: Encourager et promouvoir le progrès de l'éducation au moyen de bourses d'études et autre aide aux étudiants et aux universités canadiennes, sous le nom de « Fondation Populaire des bourses d'études inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $10,000.Le siège social de la corporation est 112, rue St-Paul ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24053-o 407-68 Galerie d'Art La Plaza inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de février 19G8, constituant en corporation: Claude Lefebvre, 600, Fontainebleau, Jean-Claude Mercure, 697, Auteuil, et Claude Ouellette, 956, Frechette, tous trois avocats, de Laval, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de peintures, dessins, gravures, images, sculptures, objets d'art et autres produits semblables, sous le nom de « Galerie d'Art La Plaza inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 350 actions ordinaires de $100 chacune et en 500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24053-o 817-68 Les Galeries Schertle inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de février 1968, constituant en corporation: Louis Dufresne, directeur radiophonique, Carmen L.Dufresne, commerçante, épouse dudit Louis Dufresne, tous deux de 2978, Deschambault, Sainte-Foy, et Yvon Couture, comptable, 4515, 4e avenue, Charlesbourg, pour les objets suivants: Faire le commerce d'oeuvres d'art, d'artisanat, de bibelots et autres objets de décoration intérieure, sous le nom de « Les Galeries Schertle inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 390 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 2978, Deschambault, Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Fondation Populaire des bourses d'études inc.Notice is given that under Part DTI of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Michel Tanguay, businessman, 1101 Lafontaine Park, Montreal, Jacques Rolland, businessman, and Denise Archambault, housewife, wife of said Jacques Rolland, the latter two of 49 Ste-Rose, Laval, for the following purposes: To encourage and promote the progress of education through scholarships and other means to aid students and Canadian universities, under the name of \"Fondation Populaire des bourses d'études inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $10,000.The head office of the corporation is at 112 St-Paul Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 407-68 Galerie d'Art La Plaza inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Claude Lefebvre, 600 Fontainebleau, Jean-Claude Mercure, 697 Auteuil, and Claude Ouellette, 956 Frechette, all three advocates, of Laval, for the following purposes: To carry on business dealing in all kinds of paintings, drawings, engravings, pictures, sculptures, objects of art and other similar merchandise, under the name of \"Galerie d'Art La Plaza inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 350 common shares of $100 each and 500 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Laval, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 817-68 Les Galeries Schertle inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Louis Dufresne, broadcasting director, Carmen L.Dufresne, trader, wife of said Louis Dufresne, both of 2978 Deschambault, Sainte Foy, and Yvon Couture, accountant, 4515, 4th Avenue, Charlesbourg, for the following purposes: To deal in works of art, handicrafts, knick-knacks and other interior decoration objets, under the name of \"Les Galeries Schertle inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common sliares of $1 each and into 390 preferred sliares of $100 each.The head office of the company is at 2978 Deschambault, Sainte-Foy, judicial district of Quebec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 840-68 Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 840-68 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1963, Vol.100, No.U 2151 Gauthier Mining Group Ltd.Le Groupe Minier Gauthier Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968, constituant en corporation sans capital-actions: David Fleming, 65, Belvédère, Westmont, Ben Bernstein, 4004, Grey, et Jean-Paul Gagnon, 656, Filiatrault, ces deux* derniers de Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et de portefeuille et faire des explorations et recherches pour découvrir des mines et minerais, sous le nom de « Gauthier Mining (îroup Ltd.\u2014 Le Groupe Minier Gauthier Itée », avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la corporation est 426, 110, place Crémazie, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le soussecrflairc de la province, Raymond Douville.24053 386-68 General Builders Association L'Association générale des Constructeurs Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour de février 196S, constituant en corporation sans capital-actions: Ronald Bibace.183, Finchley, Henry Weitzman, 172, Eton Crescent, Micheal Zuncnshinc, 27, chemin Bclsize, Saul Luger, 190, Eton Crescent, Irwin Adclson, 31, chemin Bclsize, tous cinq de Hampstead, Morris Robinson, 4709, chemin Circle, Montréal, et Aaron Gclber, 175, Spring Grove Crescent, Outrcmont, tous les sept constructeurs, pour les objets suivants: Encourager et promouvoir les intérêts des entrepreneurs généraux, sous le nom de « General Builders Association \u2014 L'Association générale des Constructeurs ».Le montant auquel se limite la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation est de 8500,000.Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24053 836-68 Gauthier Mining Group Ltd.Le Groupe Minier Gauthier Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: David Fleming, 65 Belvedere, Westmount, Ben Bernstein, 4004 Grey, and Jean-Paul Gagnon, 656 Filiatrault, the latter two of Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment and holding company and to prospect and explore for mines and minerals, under the name of \"Gauthier Mining Group Ltd.\u2014 Le Groupe Minier Gauthier Itée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and 3,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 426, 110 Place Crémazie, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 386-68 General Builders Association L'Association générale des Constructeurs Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Ronald Bibace, 183 Finchley, Henry Weitzman, 172 Eton Crescent, Michael Zuncnshinc, 27 Belsize Road, Saul Luger, 190 Eton Crescent, Irwin Adclson, 31 Belsizc Road, all five of Hampstead, Morris Robinson, 4709 Circle Road, Montreal, and Aaron Gclber, 175 Spring Grove Crescent, Outremont, all seven builders, for the following purposes: To foster and advance the interests of general builders, under the name of \"General Builders Association \u2014 L'Association générale des Constructeurs\".The amount to which the value of the immovable property which may be owned or held by the corporation is to be limited, is $500,000.The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 836-68 The Greek Canadian National Brotherhood Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13c jour de février 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Helen Stavpidou, comptable, célibataire, 4989, Notre-Dame, Laval, George Anastasopoulos, homme d'affaires, 877, Stuart, Afstathios Favas, cuisinier, 1640, Van Home, app.2, tous deux d'Outremont, Nikitas Georgopoulos, fourreur, 1225, Bernard, app.3, Nicolaos Koutroumanos, surveillant, 1225, Bernard, app.9, Constantine Marangos, restaurateur, 4613, Park Tassos Xipolitakis, opérateur de machine, 3683, Laval, npp.3, Georges Savvides, restaurateur, 5169, Park, Kostal Ponlopoulos, barbier, 4521, Espla-nale, et Alex Vounasis, presseur, 5721-A, Esplanade, les sept derniers de Montréal, pour les objets suivants: The Greek Canadian National Brotherhood Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of February, 196S, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Helen Stavpidou, accountant, spinster, 4989 Notre-Dame, Laval, George Anastasopoulos, businessman, 877 Stuart, Afstathios Favas, cook, 1640 Van Home, Apt.2, both of Outremont, Nikitas Georgopoulos, furrier, 1225 Bernard, Apt.3, Nicolaos Koutroumanos, attendant, 1225 Bernard, Apt.9, Constantine Marangos, restaurant owner, 4613 Park, Tassos Xipolitakis, machine operator, 3683 Laval, Apt.3, Georges Sawides, restaurateur, 5169 Park, Kostal Ponlopoulos, barber, 4521 Esplanade, and Alex Vounasis, presser, 5721-A Esplanade, the latter seven of Montreal, for the following purposes: 2152 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100- année, n° U Construire, entretenir et diriger des installations A fins éducatives, culturelles, recréatives et sportives, sous le nom de « The Greek Canadian National Brotherhood ».Le montant auquel se limite la valeur des biens immobiliers que peut acquérir ou posséder la corporation est de $100,000.Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sons-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053 429-68 Les Habitations Futura inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6c jour de février 1968.constituant en corporation: Georges Lessard, constructeur, 7385, Lévesque.Anjou, Paul Cha-lifoux, comptable, 2516.St-Zotique est.Montréal, et Jean-Jacques Danis, comptable, 21, Mercier, Saint-Rapliocl-dc-l'Uc-Bizard, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Les Habitations Futura inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 400 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire de la prorince, Raymond Douville.24053-o 512-68 To construct, maintain and operate educational, cultural, recreational and sporting facilities, under the name of \"The Greek Canadian National Brotherhood\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may own is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 429-68 Les Habitations Futura inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of February, 1968, liavc been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: (ïcorges Lessard, builder, 7385 Lévesque.Anjou, Paul Chalifoux, accountant.2516 Saint-Zotiquc East, Montreal, and Jean-Jacques Dan is.accountant.21 Mercier, Saiiit-ltaphac'l-dc-l'Ilc-Bizard, for the following purposes: To carry on business as builders and general contractors, and deal in all kinds of materials, under the name of \"Les Habitations Futura inc.\", with a total capital slock of $10,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Produce.24053 512-68 Harold Standard and Associates Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1908, constituant en corporation: Morris Simon, 5501, Randall.Harry Mcdicoff, 4829.avenue Kent, tous deux gérants, et Harold Standard, administrateur de ventes, 3555.chemin Côte des Neiges, app.1709, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Créer, établir, construire et maintenir une organisation de vente ou d'achat A des fins de promotion, vente, réclame, distribution ou introduction rating: Rudolfe DuBois, electric engineer, arhara Lewis, secretary, wife of the said Rudolfe DuBois, both of 1905 Tuppcr, and Lou Tanncnbaum, advocate, 276 St.James Street West, all three of Montreal, for the following purposes: To operate a restaurant, snack bar, ice cream parlor including catering service and everything incidental thereto, under the name of \"Ice Cream Inn Ltd.\", with a total capital stock of $10.000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Place Longueuil, Shopping Center, Longueuil, judicial district of Montreal.Raymond Douvilli-:.Assistant Secretary of the Province.24053-o 1004-68 Immeubles Deux-Montagnes inc.Two Mountains Realties Inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 16th day of February, l008, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor- Rornting: Gilles Latour, insurance broker, Nicole ficolas, secretary, spinster, lioth of St-Eiistnchc, and Danielle Fortin, secretary, wife separate as to property of Michael Barry-Poole,Two Mountains, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Immeubles Dcux-Montagncs inc.\u2014Two Mountains Realties Inc.\", with a total capital stock of $30.000, divided into 3,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 37 St-Eustachc Street, Suint-Eustachc, judicial district of Terrebonne.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 5245-67 Immeubles Lussier ltéc Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gerald Lussier, garagc-kcepcr, 2922 Charland, Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, 4205 B our ret Street, both of Montreal, and David Kirshenblatt, advocate, 5636 Greenwood Avenue, Côte Saint-Luc, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Immeubles Lussier Itée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each. GAZETTE OFFICIAL GAZETTE, April G, 19G8, Vol.100, No.H 2155 Le siège social de la compagnie est 1010, rue The head office of the company is at 1010 Stc-Cathcrine, Suite 622, Montréal, district judi- St.Catherine Street, Suite 622, Montreal, judiciaire de Montréal.cial district of Montreal.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville, Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.21053 741-68 24053-o 741-68 Ingrid's Inner Circle Inc.Ingrid's Inner Circle Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies, le lieutenant- Companies Act, letters patent, bearing date the gouverneur de la province a accordé des lettres 28th day of February, 1968, have been issued by patentes, en date du 28c jour de février 1968, the Lieutenant-Governor of the Province, incor- constituant en corporation: Stanley Cytrynbaum, porating: Stanley Cytrynbaum, advocate, 234 avocat, 231, Sherator Drive, Montréal-Ouest, Sheraton Drive, Montreal West, Anne Brown, Anne Brown, 5501, Adalbert, app.215, Côte 5501 Adalbert, Apt.215, Côte Saint-Luc, and Saint-Luc, et Daphne Saunderson, 322, avenue Daphne Saunderson, 322 Elm Avenue, West- Elm, Wcstmount, ces deux dernières secrétaires, mount, the latter two secretaries, spinsters, for célibataires, pour les objets suivants: the following purposes: Faire affaires comme magasin ù rayons, sous le To carry on the business of a departmental nom de « Ingrid's Inner Circle Inc.», avec un store, under the name of \"Ingrid's Inner Circle capital total de S20.000, divise en 5,000 actions Inc.\", with a total capital stock of $20,000, ordinaires de SI chacune et en 15,000 actions divided into 5,000 common shares of $1 each privilégiées de $1 chacune.and 15,000 preferred shares of $1 each.Le siège social de la compagnie est à Montréal, The head office of the company is at Montreal, district judiciaire de Montréal.judicial district of Montreal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville, Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.21053 935-68 24053-o 935-68 Institut d'Orientation des Métiers du Québec inc.Quebec Trade Orientation Institute Inc.Institut d'Orientation des Métiers du Québec inc.Quebec Trade Orientation Institute Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies, le lieutenant- Companies Act, letters patent, bearing date the gouverneur de la province a accorde des lettres 7th day of February, 1968, have been issued by patentes, en date du 7c jour de février 1968, the Lieutenant-Governor of the Province, incor- constituant cn corporation: Joseph-Rémi Gareau, porating: Joseph-Rémi Gareau, executive, Jeanne administrateur, Jeanne d'Arc Desjardins, mena- d'Arc Desjardins, housewife, wife separate as to gère, épouse contractuellement séparée de biens property of said Joseph-Rémi Gareau, both of diiclit Joseph-Rémi Gareau, tous deux do 20, 20 Bcllevue, Sainte-Thérèse, Georges-Eugène Bellevue, Sainte-Thérèse, Georges-Eugène Ga- Gareau, professional technician, and Mabel Eas- roau, technicien professionnel, et Mabel Eastcv, tey, housewife, wife contractually separate as to ménagère, épouse contractuellement séparée «le property of said Georges-Eugène Gareau, the biens dudit Georges-Eugène Gareau, ces deux latter two of 11 Argenteuil Place, Laval, for the derniers de 11, Place d'Argenteuil, Laval, pour following purposes: les objets suivants: Établir, maintenir, organiser, administrer et To establish, maintain, organize, administer diriger une école pour fins d'orientation et pour and run a school for the vocational guidance, the lins d'enseignement des arts, des métiers et des teaching of arts, trades and technical professions, professions techniques, sous le nom de « Institut under the name of \"Institut d'Orientation des d'Orientation des Métiers du Québec inc.\u2014 Que- Métiers du Québec inc.\u2014 Quebec Trade Orien- bec Trade Orientation Institute Inc.», avec un tation Institute Inc.\", with a total capital stock capital total de 810,000, divisé en 2,000 actions of $40,000, divided into 2,000 common shares of ordinaires de S10 chacune et en 2,000 actions $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each, privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 4443, rue The head office of the company is at 4443 Drolet, Montreal, district judiciaire de Montreal.Drolet Street, Montreal, judicial district of Montreal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville, Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.-'\u20221053-o 5180-67 24053 5180-67 Institut France - Laurc inc.Institut France - Laure inc.Avis est donne qu'en vertu de la première Notice is given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies, le lieutenant- Companies Act, letters patent, bearing date the gouverneur de la province a accordé des lettres 15th day of February, 1968, have been issued by patentes, en date du 15c jour de février 1968, the Lieutenant-Governor of the Province, incor- \"instituant cn corporation: Irving Shapiro, porating: Irving Shapiro, 4957 Isabella Avenue, 1937, avenue Isabella, Paul Yaphe, 53S0, avenue Paul Yaphe, 5380 Montclair Avenue, both advo- Montclair, tous deux avocats, et Elayne Felix, cates, and Elayne Felix, secretary, wife separate secrétaire, épouse séparée de biens de Dudley as to property of Dudley E.Felix, 2030 Place B.Felix, 2030, place Henri-Bourassa, tous trois Henri-Bourassa, all three of Montreal, for the de Montréal, pour les objets suivants: following purposes: 2150 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, G avril 19G8, 100' année, n° U Exercer le commerce général «l'un institut aux fins (l'enseigner les principes de l'esthétique, les soins de la figure et du corps, sous le nom de « Institut Fruncc-I.aurc inc.», avec un capital totul de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053 170-68 Intcgron Associates Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province n accordé des lettres patentes, en date du 6e jour de février 1968, constituant cn corporation: James T.McCay, conseiller, 3460, avenue Simpson, Norman N.Genscr, avocat et conseil en ïa>\\ de la reine, 1585, avenue McGregor, tous deux de Montréal, Wolfe M.Kricdmnn, 5750, avenue Smart, Côte Saint-Luc, Simon Gulden, 5181, avenue Bourret, Montréal, tous deux avocats, Theslvn Miller, 322.Des Ohlats.LaSalle.et Gladys Kohalenko, 1419, avenue Rolland, Verdun, ces deux dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: Fournir les services d'un consortium consultatif dans le but de donner un service coordonné d'idées et de conseils sur le développement intégral des organismes, des institutions, des gouvernements, des projets et des programmes, qu'ils soient local, national ou international, sous le nom de « Intcgron Associates Incorporated », avec un capital total de $10.000, divisé en 1.000 actions classe « A » d'une valeur au pair de $1 chacune, cn 1,000 actions classe « B » d'une valeur ou pair de SI chacune et en 380 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053 523-68 Intercity Food Services Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province n accordé des lettres patentes, cn date du 8e jour de juin 1967, autorisant la fusion de « Intercity Food Services Ltd.», et « Hcr-Sel Enterprises Ltd.», toutes deux constituées cn corporation cn vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes en date du 16 décembre 1965 et du 21 avril 1961, respectivement, pour les objets suivants: Exploiter des restaurants et faire le commerce de denrées alimentaires, articles, produits et marchandises de toutes sortes, avec un capital total de $100,000, divisé en 9,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et cn 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le nom de la nouvelle compagne est « Intercity Food Services Inc.».Le siège social de la compagnie est 1100, Murllioro Drive, Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.To carry on business generally as an institute for the teaching of esthetic, facial and body care, under the name of \"Institut France-Laure inc.\", with a total capital stock of S 19.039, divided into 10,000 common shares of 81 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of tlie Province.24053-o 170-63 Intcgron Associates Incorporated Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing (late the 6th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: James T.McCoy, consultant, 3460 Simpson Avenue, Norman N.denser, advocate and Queen's Counsel, 1585 McGregor Avenue, both of Montrcol, Wolfe M.Fricdmon, 5750 Smart Avenue, Côte Saint-Luc, Simon Gulden, 5181 Bourret Avenue, Montreal, both advocates, Thcslyn Miller.322 Des Obluts.LaSullc, and Gladys Kobalcnko, 1419 Rolland Avenue, Verdun, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To provide the services of a consulting consortium for the purpose of furnishing an integrated conceptual and counselling service on the integral development of organizations, institutions, governments, projects and programs, whether local, nationul or international, under the name of \"Intcgron Associates Incorporated\", with a total capital stock of $10.000, divided into 1.000 class \"A\" shares having a par value of $1 each, 1,000 class \"B\" shares having n par value of $1 each and 380 preferred shares having a pur value of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of lite Province.24053-o 623-68 Intercity Food Services Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of June, 1067, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, authorizing the amalgamation of \"Intercity Food Services Ltd.\", and \"Hcr-Scl Enterprises Ltd.\", both incorporated under the said Part I of the Com- Einies Act, by letters patent dated, respectively, lecember 16, 1965, and April 21, 1961, for the following purposes: To operate restaurants and deal in food products, goods, wares and merchandise of all kinds, with a total capital stock of SIOO.OOO.divided into 9,000 common shares of the par value of $10 each and 100 preferred shares of the par value of $100 each.The name of the new company is \"Intercity Food Services Inc.\".The head office of the company is at 1100 Marlboro Drive, Mount Royal, judicial district of Montreal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053 2612-67 \u2014 1382/67 Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 2612-67 \u2014 1382/67 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.U 2157 Investissements Perron inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968, constituant en corporation: Gérard Guillemette, comptable, Rachel Perron, ménagère, épouse séparée de biens de Grégoire Dontigny, tous deux de Saint-Tite, et Alphonse Cinq Mars, vendeur, 273, Cloutier, Loretteville, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Investissements Perron inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 3860, boulevard Hamel, Les Saules, district judiciaire de Québec.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24053-o 924-68 Irene Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres palcntcs, en date du 27e jour de décembre 1967, constituant en corporation: Menashc Broder, 5715, Léger, Cote Saint-Luc, C.Johsua Boren-slcin, 4652, Vézina, tous deux avocats, et Esther Frecdman, secrétaire, fille majeure, 3250, Ellen-dalc, app.214, ces deux dernières de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille ( holding), sous le nom de * Irene Holdings Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune, en 25,000 actions privilégiées classe « A » de $1 chacune et in 5,OO0 actions privilégiées classe « B » de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.5415-67 L'1053 J.M.autos limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres palcntcs, en date du 20c jour de février 1968, constituant en corporation: Jean-Marie Matteau, commerçant, Murielle L.Matteau, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Jean-Marie Matteau, tous deux de 150, 6e rue, Grand'Mèrc, et Réjean Perron, comptable, Aiicienne-Lorette, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « L M.autoî limitée », avec un capital total de $125,000, divisé en 7,500 actions ordinaires de $10 eh icune et en 5,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Grand' Mère, district judiciaire de Saint-Maurice.Investissements Perron inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gérard Guillemette, accountant, Rachel Perron, housewife, wife separate as to property of Grégoire Dontigny, both of Saint-Titc, and Alphonse Cinq Mars, salesman, 273 Cloutier, Loretteville, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Investissements Perron inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 3860 Hamel Boulevard, Les Saules, judicial district of Quebec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 924-68 Irene Holdings Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of December, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Menashe Broder, 5715 Léger, Côte Saint-Luc, C.Joshua Borenstein, 4652 Vézina, both advocates, and Esther Freedman, secretary, fille majeure, 3250 Ellendale, Apt.214, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"Irene Holdings Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of 81 each, 25,000 Class \"A\" preferred shares of $1 each and 5,000 Class \"B\" preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.5415-67 24053-o J.M.autos limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Marie Matteau, trader, Murielle L.Matteau, housewife, wife contractually separate as to property of said Jean-Marie Matteau, both of 150, 6th Street, Grand'Mèrc, and Réjean Perron, accountant, Ancienne-Lorette, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers and to deal in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"J.M.autos limitée\", with a total capital stock of $125,000, divided into 7,500 common shares of $10 each and into 5,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Grand' Mère, judicial district of Saint-Maurice.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24053-o 780-68 Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 780-68 2158 G.Y/.KTTK OFFICIELLE DE QUÉBEC, G avril 19GS, 100- année, n° H J.& W.Investments Inc.J.& W.Investments Inc.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de In province a accordé des lettres patentes, cn date du 5e jour de février 1968, constituant en corporation: Max S.Kaufman, 574, Claremont, Westmount, J.Roy Hoffman, 5616, l'incdalc, Côte Saint-Luc, tous deux avocats et Conseils en Loi de la Reine, et Sydney 15.Scdcrolf, avocat, 80, Crestwood, Montréal-ouest, pour les objets suivants: Faire le commerce d'une compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom de « J.& W.Investments Inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est ù Montréal, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire tie la province, Raymond Douville.24053 625-68 Jacobi's Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, cn date du 16c jour de février 1968, constituant en corporation: Stanley L.Cytrynbaum, 95, Roxton Crescent, Montréal-Ouest, Murk Edmund Gordon, 36, Roxborough, West-mount, tous deux avocats, Klayne P.' Felix, secrétaire, épouse de Dudley Felix, 2030, Place Hcnri-Bourassu, app.25, et Margaret Ivanisko, secrétaire, fille majeure, 5515, place Basilc-Patc-naude, ces deux dernières de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de vêtementset d'accessoires vestimentaires de toutes sortes, sous le nom de « Jacobi's Inc.», avec un capital total de $50.000.divisé cn 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et cn 4.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est ù Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24053 735-68 Jardins St-Hubcrt inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, cn date du 26e jour «le février 1968, constituant cn corporation: Pierre Bourque, 48, Ch'irtrcs, Dollard-des-Ormeaux, Claude Benoit, 1758, Jacqucs-Lemaistre, Montréal, Joseph-Frédéric Bcaubien, 376, Redfern, app.28, Westmount, tous trois avocats, et Charline Harvcy, secrétaire, fdlc majeure, 172, Centrale, LaSalle, pour les objets suivunts: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Jardins St-Hubcrt inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et cn 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Hubert, district judiciaire de Montréal.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Max S.Kaufman, 574 Claremont, Westmount, J.Roy Hoffman, 5616 Pinedalc, Côte Saint-Luc, both advocates and Queen's Counsels, and Sydney B.Scderoff, advocate, 80 Crestwood, Montreal West, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"J.& W.Investments Inc.\", with a total capital slock of S40.000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $ 100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 625-68 Jacobi's Inc.Notice is given that untler Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of February, 1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Stanley L.Cytrynbaum, 95 Roxton Crescent, Montreal West, Mark Edmund Gordon, 36 Roxlwrough, Westmount, lioth advocates, Elayne P.Felix, secretary, wife of Dudley Felix, 2030 Place Henri-Bourassa, No 25, and Margaret Ivanisko.secretary, spinster of the full age of majority, 5515 Place Basilc-Putcnaudc.the latter two of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Jacobi's Inc.\", with a total capital stock of $50.000.divided into 10.000 common shares of the par value of $1 each and 4.000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 735-68 Jardins St-Hubcrt inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of February, 1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Bourque, 48 Chartres, Dollard-dcs-Ormcaux, Claude Benoit, 1758 Jacques-Lc-maistrc.Montreal, Joseph-Frédéric Bcaubien, 376 Redfern, Apt.28, Westmount, all three advocates, and Charline Harvey, secretary, spinster of the full age of majority, 172 Centrule, LaSalle, for the following purposes: To carry on business as real estate and construction company, under the name of \"Jardins St-Hubcrt inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 100 common shares of $10 each and 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Saint-Hubert, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 884-63 Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 884-68 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6.1968, Vol.100, No.U 2159 Jet Uranium Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres putentes, en date du 9e jour de février 1968, constituant en corporation: Julius liriskin, avocat et conseil en Loi de la reine, 134, Finchley, Aslicr, Kalin, avocat, 484, Dufferin, tous deux de Hampstead, Grace Blackctt, 5622, ouest, rue Sherbrooke, Delphine Matthew, 3455, Aylmer, et June Finn, 1800, de Salabcrry, ces trois dernières secrétaires, célibataires, de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'une compagnie minière, sous le nom de « Jet Uranium Limited » (No Personal Liablility), avec un capital total de 53,000,000, divisé en 3,000,000 d'actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie est A suite 1501, 1, place Ville Marie, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24053 630-68 Jet Uranium Limited (No Personal Liability) Notice is given that under the provisions of the Mining Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Julius Briskin, advocate and Queen's Counsel, 134 Finchley, Asher Kahn, advocate, 484 Dufferin, both of Hampstead, Grace Blackett, 5622 Sherbrooke Street West, Delphine Matthew, 3455 Aylmer, and June Finn, 1800 de Salaberry, the latter three secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a mining company, under the name of \"Jet Uranium Limited\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $3,000,000, divided into 3,000,000 common shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at suite 1501, 1 Place Ville Marie, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 630-68 La Jeune Chambre de Cagnon inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 5c jour de mars 1968, Constituant en corporation sans capital-actions: Iînger Cyr, surveillant, Gilles Moisan, commis de bureau, et Donald Lévesque, électricien, tous trois de (ïagnon, pour les objets suivants: Agir au bénéfice des jeunes en les intéressant au progrès économique, social et civique de leur milieu, sous le nom de « La Jeune Chambre de Gagnon inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la cor-wration, est de $100,000.Le siège social de la corporation est A Gagnon, district judiciaire de Hauterivc.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.21053-o 684-68 La Jeune Chambre de Gagnon inc.Notice is given that under Part ni of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of March, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Roger Cyr, supervisor, Gilles Moisan, office clerk, and Donald Lévesque, electrician, all three of Gagnon, for the following purposes: To act for the benefit of youth by interesting them in the economic, social and civic progress of their environment, under the name of \"La Jeune Chambre de Gagnon inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation is at Gagnon, judicial district of Hauterive.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 684-68 Julian Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, cn date du 22c jour de février 1968, (on-tituant en corporation: Conrad Shatner, 1728, Fulton.Frank (iodine, 4800 Côte des Neiges, tous deux avocats, et Rhoda Cohen, secrétaire, célibataire.d'Age majeur.6427.MacDonald, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de place -mentt, sous le nom de « Julian Investment Corporation », avec un capital total de $40,000.divisé en 100 actions ordinaires de $1 chacune et 390 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est A Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.21053 876-08 Know lion construction inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres Julian Investment Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of February, 1968, liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Conrad Shatner, 4725 Fulton, Frank Godine.4800 Côte des Neiges, both attorneys and Rhoda Cohen, secretary, spinster of the full age of majority, 6427 MacDonald, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Julian Investment Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $1 each and 399 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 876-68 Knowlton construction inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of February, 1968, have been issued by 2160 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100' année, n° Ji patentes, en date du 9c jour de février 1968, constituant en corporation: Michel Ricci, commerçant, William Ricci, commerçant, et Maria Piaccnte, ménagère, épouse commune en biens dudit William Ricci, tous trois de 9239, Esplanade, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Knowlton construction inc.», avec un capital total de $40,000, divisé cn 15.000 actions ordinaires de $1 chacune et cn 2,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est ù Knowlton, district judiciaire de Bedford.Le sous-secretaire de la produce, Raymond Douville.24053-o 564-68 Knox Holdings Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20c jour de février 1968, constituant en corporation: Herbert Birkctt McNally.4006, avenue Montrose, Paul Frederick Dingle, 528, avenue Mount Peasant, tous deux de Westmount, et John Howard Dawson, 28.chemin Stratford, Hampstead.tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de portefeuille, sous le nom de « Knox Holdings Limited », avec un capital total de $250.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $1 cliacunc et 248,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est ù Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la prorince, Raymond Douville.24053 675-68 Korvet Shopper's Discount Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première l>artie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 9c jour de février 1968.constituant cn corporation: Frederick Zipes, étudiant.Henry Zipes, négociant, tous deux de 2777, avenue Ekers.Montréal, et Gerald J.(îoodman.vendeur, 1026, 100e Avenue, Laval, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de toutes sortes de produits, d'articles et de marchandises, sous le nom de « Korvet Shopper's Discount Ltd.», avec un capital total de $40.000, divisé cn 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et cn 39.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 6484, avenue Victoria, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la prorince, Raymond Douville.24053 634-68 L.G.Electric Appliance Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, cn date du 14e jour de février 1968, constituant en corporation: Normand Duval, avocat, 2185, Nicolas-Perrot, Chantai Bachini, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, 656, Place Fleury.tous deux de Montréal, et Guy Tremblay, comptable.10817, St-Julien, Montréal-Nord, pour les objets suivants: the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Michel Ricci, merchant, William Ricci, merchant, and Maria Piacente, housewife, wife common as to property of the said William Ricci, all three of 9239 Esplanade, Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders and general contractors, under the name of \"Knowlton construction inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 15.000 common shares of $1 each and 2,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Knowlton, judicial district of Bedford.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 564-68 Knox Holdings Limited Notice is given that under Part I of the Com-MUiics Act, letters patent, bearing date the 20th duy of February.1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: HerlK-rt Birkett McN'ally.4(H)6 Montrose Avenue.Paul Frederick Dingle, 528 Mount Pleasant Avenue, lioth of Westmount.and John Howard Dawson, 28 Stratford Roud, Hampstead, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"Knox Holdings Limited\", with a total capital stock of S250.000.divided into 2,000 common shares of $1 each and 248,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dor ville, Assistant Secretary of the Prorince.24053-o 675-68 Korvet Shopper's Discount Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing dale the 9th \u2022lay of February.1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Frederick Zipes, student, Henry Zipes, mercliant.both of 2777 Ekcrs Avenue, Montreal, and Gerald J.Goodman, salesman, 1026, 100th Avenue, Laval, for the following purposes: To manufacture and deul in all kinds of products, articles aud merchandise, under the name of \"Korvet Shopper's Discount Ltd.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each and 39,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company is at 6484 Victoria Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Produce.24053-o 034-68 L.G.Electric Appliance Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 14th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Normand Duval, advocate, 2185 Ni colas-Perrot, Chantai Bachini.secretary, spinster, using her rights, 656 Fleury Place, both of Montreal, and Guy Tremblay, accountant.10817 St-Julien, Montreal-North, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.U 2161 Faire le commerce de toutes sortes d'appareils cm systèmes de chauffage, sous le nom de « L.G.Electric Appliance Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de $ 100 chacune et cn 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 7714, rue l.ajcuncsse, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secretaire de la produce, Raymond Douville.210.Î3-o 494-68 Lapointe, Associés inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 14c jour de février 1968, constituant en corporation: Y'.-Anselme Lapointe, décorateur, 22, Doré, Saint-Félix-du-Cap-Rougc, Jean-Marie Lapointe, artiste, 8182, Montri-chiml.Anjou.Guy Lapointe, gérant général.37, rue de Louisiannc.Rcpentigny, et Gabriel Laïc \u2022inte.avocat, 2501, Tour de la Bourse.Place Victoria, Montréal, pour les objets suivants: Donner des consultations et des avis, préparer des études, dessins, plans et devis cn matière d'esthétique industrielle et commerciale et de graphisme, sous le nom de « Lapointe, Associés Il e .avec un capital total de $40.000.divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.sous-seerftaire de la prorince, Raymond Douville.240584 319-68 To deal in all kinds of appliances or heating systems, under the name of \"L.G.Electric Appliance Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common sliares of $100 each and 200 preferred sliares of $100 each.The head office of the company is at 7714 Lajeuncssc Street, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 494-68 Lapointe, Associes inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Y.-Ansclme Lapointe, decorator, 22 Doré, Saint Félix-du-Cap-Rougc, Jean-Marie Lapointe, artist, 8182 Montrichard, Anjou, Guy Lapointe, general manager, 37 De Louisianne Street, Repentigny, and Gabriel Lapointe, advocate, 2501 Tour de la Bourse, Place Victoria, Montreal, for the following purposes: To give consultations and advice, prepare studies, drawings, draughts and estimates in the field of industrial, commercial, aesthetic and graphic arts, under the name of \"Lapointe, Associés inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common sliares of $10 each and 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Saint-Foy.judicial district of Quebec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 319-68 Latin American Enterprises Ltd.Lea Entreprises Latines Américaines Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-Roiivcrneur nie la province a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de février 196S, constituant cn corporation: Irving Shapiro, 4957, Isabella, Montréal, Stanley L.Cytrynbaum, 95, Roxton Crescent, Montréal-Ouest, tous deux avocats, Elayne P.Felix, secrétaire, épouse » parée de biens de Dudley E.Fclix, 2030, Place Heiiri-Hourassa, Montréal, et Erica Hume, secrétaire, épouse séparée de biens de John B.Iliinic, 2450, Athlone, Mont-Royal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de toutes sortes de produits, d'articles et de marchandises, sous le nom de « Latin American Enterprises Ltd.\u2014 Les Entreprises Latines Américaines ltéc », a\\ ce un capital total de $40,000, divisé en 10,000 allions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et en 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.le siège social de la compagnie est à Montréal, ilislrict judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24053 736-68 Leader Trading Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres Patentes, cn date du 16e jour de février 1968, constituant en corporation: Irving Halperin, Latin American Enterprises Ltd.Les Entreprises Latines Américaines Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Irving Shapiro, 4957 Isabella, Montreal, Stanley L.Cytrynbaum, 95 Roxton Crescent, Montreal West, both advocates, Elayne P.Felix, secretary, wife separate as to property of Dudley E.Felix\", 2030 Place Henri-Bourassa, Montreal, and Erica Hume, secretary, wife separate as to property of John B.Hume, 2450 Atlilone, Mount Royal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"Latin American Enterprises Ltd.\u2014 Les Entreprises Latines Américaines Itée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common sliares of a par value of $1 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 736-68 Leader Trading Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Irving Halperin, 5609 Queen Mary 21G2 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, G avril 19G8, ICO' année, n° U 5609, chemin tic la Reine-Marie, Hampstead, Daniel Morris, 6165, avenue Notre-Dame-dc-(îrflee, tous deux avocats, et Georgette Lavoic, secretaire, célibataire, 9340, Lajeunessc, ces tleux dernières de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de marchandises, d'articles, de produits et de toutes sortes d'objets de toutes natures, sous le nom de « Leader Trading Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé cn 20.000 actions ordinaires de $1 chacune et cn 20,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053 740-68 Letournair inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, cn date du 28e jour de février 1968, constituant cn corporation: Claude Létourneau, 350, boulevard Queen, Saint-Lambert, Adrien Létourneau, 521, Lecorbusier, tous deux entrepreneurs cn construction, et Paul Lemieux, avocat et conseil cn Loi de la reine, 400, Vauque-lin, ces deux derniers de Rcloeil, pour les objets suivants: Établir, maintenir et diriger des écoles tic vol et manufacturer et faire le commerce «l'avions, moteurs «l'avions et «le toutes machineries, sous le nom de < Letournair inc.», avec un capital total de $40,000, divisé cn 500 actions ordinaires d'une valeur nominale tie $1 chacune et en 3,950 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 365, boulevard Laurier, Rcloeil, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 970-68 La Ligue des Propriétaires de Montréal-Nord inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé des lettres patentes, en date du 19c jour de février 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Guy Heaudet.entrepreneur.11715.rue l'Archevêque, Maurice-G.Boisvert, agent industriel, 5591, rue des Roses, Jean-Louis Chevalier, gérant «les ventes, 11956, rue Pigeon, Claude Laçasse, ingénieur, 5816, rue Mauricc-Dupjessis, Paul Rousseau, agent de relations industrielles, 5607, rue des Jacinthes, et Roland Vaillancourt, professeur, 10372, rue Paris, tous six de Montréal-Nord, pour les objets suivants: Développer l'esprit civique des membres et des citoyens en général et défendre et promouvoir leurs intérêts, sous le nom de « La Ligue des Propriétaires de Montréal-Nord inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $50,000.Le siège social de la corporation est A Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Road, Hampstead, Daniel Morris, 6165 Notrc-Dame-de-Grûce Avenue, both advocates, and Georgette Lavoie, secretary, spinster, 9340 Lajeunessc, the latter two of Montreal, for the following purposes: To deal in gootls, wares, products and merchandise of any kind and nature, under the name of \"Leader Trading Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20.000 common shares of $1 each and 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 740-68 Letournair inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Claude Létourneau, 350 Queen Blvd., Saint-Lambert, Adrien Létourneau, 521 Lecorbusier, both building contractors, and Paul Lemieux, advocate and Queen's Counsel, 409 Vauquclin, the two latter of Beloeil, for the following purposes: To establish, maintain and manage flying schools, antl to manufacture and ileal in airplanes, airplane motors and all machinery, under the name of \"Letournair inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 500 common shares of a nominal value of 81 each and 3,950 preferred shares of a nominal value of 810 each.The head office of the company is at 365 Laurier Blvd., Beloeil, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 970-68 La Ligue des Propriétaires de Montréal-Nord inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Guy Beaudct, contractor, 11715 L'Archevêque rue, Mauricc-G.Boisvert, industrial agent, 5591 des Roses Street, Jean-Louis Chevalier, sales manager, 11956 Pigeon Street, Claude Laçasse, engineer, 5816 Maurice-Duplessis Street, Paul Rousseau, industrial relations agent, 5607 des Jacinthes Street, and Roland Vaillancourt, teacher, 10372 Paris Street, all six of Montreal-North, for the following purposes: To develop the civic spirit of its members and of citizens in general and to uphold anil promote their interests, under the name of \"La Ligue des Propriétaires de Montréal-Nord inc.\".The amount to which is limited the value of the immovables that may be acquired anil owned by the corporation is $50,000.The head office of the corporation is at Montreal-North, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 784-6S Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 784-68 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, So.U 2163 Librairie Classique de Hull Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968, i (instituant en corporation: Gilles Perron, libraire, May (Jagnon, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Gilles Perron, tous deux de Lucerne, et A.-Fernand Piché, libraire, 200, Terrasse Rideau, Ottawa, province d'Ontario, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeurs, éditeurs, libraires et exploiter une agence de publicité, sous le nom île « Librairie Classique de Hull Itée », avec un capital total de 840,000, divisé cn 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 135, rue Hotel de Ville, Hull, district judiciaire de Hull.Le soiu-eecretaire de la province, Raymond Douville.2I053-o 815-68 Loisirs Sac Spécialité inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Lui des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29c jour de février 1968, constituant en corporation sans capital-actions: André Jalhcrt, opérateur, 214, 96c avenue, Marcel Éthicr, 560, 99e avenue, tous deux de Poiiite-aux-Trcmbles, et Claude Campcau, 6955, Iloeliclaga, app.4, Montréal, ces deux derniers imprimeurs, pour les objets suivunts: L'organisation des loisirs, sous le nom de \u2022' Loisirs Sac Spécialité inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $10,000.Le siège social de la corporation est a Pointeaux-Trembles, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.2I053-o 947-68 Librairie Classique de Hull Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Perron, librarian, May Gagnon, housewife, wife contractually separate as to property of said Gilles Perron, both of Lucerne, and A.-Fernand Piché, librarian, 200 Rideau Terrasse, Ottawa, Province of Ontario, for the following purposes: To carry on business as printers, publishers, book-sellers and to operate an advertising agency, under the name of \"Librairie Classique de Hull Itée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 ecah.The head office of the company is at 135 Town Hall Street, Hull, judicial district of Hull.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 615-68 Loisirs Sac Spécialité inc.Notice is given that under Part HI of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: André Jalbert, operator, 214.96th Avenue, Marcel f.thier, 560.99th A venue, both of Pointe-aux-Trcmbles, and Claude Campeau, 6955 Hochelaga, Apt.4, Montreal, the latter two printers, for the following purposes: The organization of a recreational centre, under the name of \"Loisirs Soc Spécialité inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $10,000.The head office of the corporation is at Pointeaux-Trembles, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.24053 947-68 Longborn Marketing & Franchising Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de février 1968, constituant cn corporation: Norman S.Kessncr, 1555, Uonavista, app.405, Montréal, Lawrence L.l'ïigel, 5711, Edgemorc tous deux avocats, et Anne Brown, secrétaire, célibataire, 5501, Adalbert, app.215, ces deux derniers de Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Mettre sur le marché, vendre et distribuer des franchises concernant les commerces suivants: fi-taurants, produits alimentaires et tous autres articles de commodité se rapportant au restaurant ou au commerce d'alimentation, sous le nom de < Longhorn Marketing & Franchising Corp.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur nu pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Longhorn Marketing & Franchising Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Norman S.Kcssncr, 4555 Bonavista, Apt.405, Montreal, Lawrence L.Fligel, 5711 Edgemore, both advocates, and Anne Brown, secretary, spinster, 5501 Adalbert, Apt.215, the latter two of Côte Saint-Luc, for the following purposes: To market, sell and distribute franchises of the following items: restaurants, food products and all other commodities relating to the restaurant or food trade, under the name of \"Longhorn Marketing & Franchising Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and 2,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-0 801-68 Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24053 801-68 2164 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100' année, n° H Lonmont Inc.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de février 1968, constituant en corporation: Raymond Eric Parsons, 11, chemin De Casson, Graham Neshitt, 250, avenue Clarke, et C.J.Michael Flavell, 4643, ouest, rue Sherbrooke, tous trois avocats, de W c-tmount, pour les objets suivants: Exploiter des omnibus, autobus, ou véhicules pour le transport des passagers et des marchandises, sous le nom de « Lonmont Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24053 672-68 Lucerne Dress (1968) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de novembre 1968, constituant en corporation: Peter Segal, fabricant, 34, avenue Gazaille, Dollard-des-Ormeaux, Jack Rubin, administrateur, 123, Springrove Crescent, Outremont, Alan M.Stein, 5042, Ponsard, Montréal, et Jeanne Khazzam, 44, avenue Sunnyside, Westmount, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce du vêtement et des articles vestimentaires de toutes sortes, sous le nom de « Lucerne Dress (1968) Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24053 665-68 Lyons Discount Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, cn date du 12e jour de février 1968, constituant en corporation: Lawrence L.Fligel, 5711, Edgcmore, Saul Handclraan, 5532 Rosc-dale, tous deux avocats, de Côte Saint-Luc, Doreen Bertin, 68, 19e Avenue, Lachine, Anne Brown, 5501, Adalbert, Côte Saint-Luc, et Daphne Saunderson, 322, Elm, Westmount, ces trois dernières secrétaires, célibataires, dans le plein exercice de leurs capacités légales, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de « Lyons Discount Corp.», avec un capital total de $40,000, divisé cn 5,000 actions ordinaires de $1 chacune et 35,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053 628-68 M & R Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première part ie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, cn date du 9e jour de février 1968, constituant cn corporation: Henry Zipes, mar- I on mont Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Raymond Eric Parsons, 11 Do Casson Road, Graham Ncshitt, 250 Clarke Avenue, and C.J.Michael Flavell, 4643 Sherbrooke Street West, all three advocates, of Westmount, for the following purposes: To operate omnibuses, motor buses or vehicles for the carrying of passengers or goods, under the name of \"Lonmont Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 4,000 common sliares of $10 each.The head oflicc of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 672-68 Lucerne Dress (1968) Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Peter Segal, manufacturer, 31 Gazaille Avenue, Dollard-dcs-Ormcaux, Jack Rubin, executive, 123 Springrove Crescent, Outrcmont, Alan M.Stein, 5042 Ponsard, Montreal, and James Khazzam, 44 Sunnysidc Avenue.Westmount, the latter two advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Lucerne Dress (196*) Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into iu.000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 665-68 Lyons Discount Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of February, 1968, have licen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Lawrence L.Fligcl, 5711 Edge-more, Saul Handelman, 5532 Roscdale.both advocates, of Côte Saint-Luc, Dorccn Bcrtin, 68, 19th Avenue, Lachinc, Anne Brown, 5501 Adalbert, Côte Saint-Luc, and Daphne Saunderson, 322 Elm, Westmount, the latter three secretaries, spintcrs, in the full exercise of their legal capacities, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Lyons Discount Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of $1 each and 35.000 preferred sliares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 628-66- M & R Holdings Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor porating: Henry Zipes, merchant, Miriam Mero QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6.19G8, Vol.100, No.U 2165 cliant, Miriam Mcrovitz, ménagère, épouse -éparéc de biens dudit Henry Zipes, et Frederick Zipes, étudiant, tous trois de 2777, avenue Kkers, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille, sous le nom de « M & R Holdings Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et cn 39.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 cliacunc.Le siège social de la compagnie est 2777, avenue Ekers, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.34508 631-68 Mail-Mart Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, cn date du 9e jour de février 1968, constituant en corporation: Henry Zipes, marchand, Frederick Zipes, étudiant, tous deux de 2777, Ekers.Montréal, et Gerald .F.Goodman, vendeur.1026.100e Avenue, Laval, pour les objets suivants: Exercer le commerce et l'industrie de toutes sortes de produits, articles et marchandises, sous le nom de « Mail-Mart Inc.\", avec un capital total de $40.000.divisé en 10.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI cliacunc et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 6484, avenue Victoria, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le 30u.i-.iecrftairc de la province, Raymond Douville.24503 632-68 Maison Rita inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de février 1968, constituant cn corporation : Edward J.Druker, 5768, McMurray, Jack Boidman, 5320, Mac-donald, tous deux avocats, de Côte Saint-Luc, et Charmian Silver, secrétaire, épouse séparée de biens de Don Silver.40.place Côte Vcrdu, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Confectionner des vêtements et articles vestimentaires de toutes sortes, en faire le commerce, sous le nom de « Maison Rita inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3.0C3 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de lu compagnie est 2732, avenue Ekers, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24053 804-68 Manufacture Farbstein ltéc Farbstein Factory Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de février 1968, constituant en corporation: Jack Berkowitz, Mervyn N.Rosenstein, tous deux avocats, de 485, rue McGill, suite 1006, Montréal, et Morris Rickel, gérant, 210 chemin Finchley, Hampstead, pour les objets suivants: vitz, housewife, wife separate as to property of the said Henry Zipes, and Frckerick Zipes, student, all three of 2777 Ekers Avenue, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a holding com- Cny, under the name of \"M & R Holdings d.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each and 39,000 preferred sliares of a par value of $1 each.The head office of the company is at 2777 Ekers Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.24503-0 631-68 Mail-Mart Inc.Notice is given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, !>earing date the 9th day of February, 1968, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Henry Zipes, merchant, Frederick Zipes, student, both of 2777 Ekers, Montreal, and Gerald J.Goodman, salesman, 1026, 100th Avenue, Laval, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"Mail-Mart Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and 30.000 preferred sliares of a par value of $1 each.The head office of the company is at 6484 Victoria Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24503-o 632-68 Maison Rita inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dote the 22nd day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Edward J.Druker, 5763 McMurray, Jack Boidman, 5320 Macdonald, both advocates, of Côte Saint-Luc, and Charmian Silver, secretary, wife separate as to property of Don Silver, 40 Place Côte Vertu, Saint-Laurent, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Maison Rita inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 2732 Ekers Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 804-68 Manufacture Farbstein Itée Farbstein Factory Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jack Berkowitz, Mervyn N.Rosenstein, both advocates, of 485 McGill Street, Suite 1006, Montreal, and Morris Rickcl, manager, 210 Fincldey Road, Hampstead, for the following purposes: 2166 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100' année, n° U Exercer le commerce et l'industrie du vêtement et article vestimentaire de toutes sortes, sous le nom de « Manufacture Farbstein ltéc \u2014 Farbstein Factory Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé cn 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 485, rue McGill, suite 1006, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la province, H av.mon n Douville.24053 657-68 Marauda équipement inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968, constituant en corporation: Edouard Maranda, industriel, Lisette Maranda, secrétaire, fille majeure, et Maurice Maranda, mécanicien, tous trois de Sainte-Aurélic, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom «le c Maranda équipement inc.», avec un capital total «le 8100,000, divisé cn 300 actions ordinaires de $100 chacune et en 700 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Georges, comté «le Beauce, district judiciaire de Beauce.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24053-o 595-68 Marché Hardy inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968, constituant en corporation: Jacques Taschcrcau, 315, avenue Laurier, François Rainvillc, 1348, Frontenac, tous deux notaires, «le Québec, et Pauline Cantin, secrétaire, fille majeure, Lorct-tevillc, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers-bouchers, sous le nom de « Marché Bardy inc.», avec un capital total de 860,000, divisé cn 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et cn 590 actions privilégiées de $100 cliacunc.Le siège social de la compagnie est il Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24053-o 925-68 Julien Martin & fils Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 15c jour de février 1968, constituant cn corporation: Julien Martin, entrepreneur, Odette Côté, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Julien Martin, tous deux de 281, rue de Salaberry.Laurcntidcs, et Muguette Gagné, secrétaire, fille majeure, 1000, rue Perrcault, Joliette, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en «xinstruction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le To manufacture and deal in clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Manufacture Farbstein Itée \u2014 Farbstein Factory Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common sliares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 485 McGill Street, Suite 1006, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 657-68 Maranda équipement inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th «lay of February, 196S, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Edouard Maranda, industrialist, Lisette Maranda, secretary, spinster of the full age of majority, and Maurice Maranda, mechanic, all three of Saintc-Aurélie, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers, and to deal in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"Maranda équipement inc.\", with a total capital stock of $100.000, divided into 300 common sliares of $100 each and 700 preferred shares of $103 each.The head office of the company is at Saint-Georges, county of Beauce, judicial district of Beauce.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 595-68 Marché Bardy inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacques Taschereau, 315 Laurier Avenue, François Rainvillc, 1348 Frontenac, both notaries of Quebec, and Pauline Cantin, secretary, spinster of the full age of majority, Lorcttcville, for the following purposes: To carry on business as grocers-butchers, under the name of \"Marché Bardy inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and into 590 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Quebec, judicial district of Quebec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 925-68 Julien Martin & fils Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 15th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Julien Martin, contractor, Odette Côté, housewife, wife contractually separate as to property of the said Julien Martin, ImhIi of 281 de Salaberry street, Laurcntidcs.and Muguette Gagné, secretory, spinster of the full age of majority, 1000 Perrcault street, Joliette, for the following purposes: To carry on business as builders and general contractors and deal in all kinds of materials, under the name of \"Julien Martin & fils Itée\". QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 19G8, Vol.100, No.Ik 2167 nom de « Julien Martin & fils Itée », avec un capital total dc $60.000.divisé cn 600 actions ordinaires dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est A Laurcntidcs, district judiciaire dc Joliette.Le sous-secretaire dc la prorince, Raymond Douville.24053-o 708-08 McMarjo Manufacturers Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour dc février 1968, constituant en corporation: Raymond Eric Par-sons, 11, chemin De Casson, D.Terence Dingle, 601, avenue Lansdownc, et C.J.Michael Fla-vell.4043 ouest, rue Sherbrooke, tous trois avocats, dc Westmount, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce du fer, dc l'acier et dc tous autres métaux, allant du minerai jusqu'à ses produits finis, sous le nom dc « McMarjo Manufacturers Limited », avec un capital total de $40,000.divisé cn 400 actions ordinaires dc $100 cliacunc Le siège social dc la compagnie est u Sherbrooke, district judiciaire dc Saint-François.Le sous-seerftaire de la prorince, Raymond Douville.84053 885-08 Mine Manufacturing Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, cn date du 29e jour dc février 1908, constituant en corporation: Asher Kahn, avocat, 4SI, chemin Dulfcrin, Hampstead, Grace Blac-kett.5022, Sherbrooke, et Delphine Matthew, 3155, rue Aylmer, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce dc toutes sortes de métaux, sous le nom dc < Mine Manufacturing Co.Ltd.», avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et cn 300 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est ù Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.21053 910-08 Les Miroirs Directionnels inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1968, constituant en corporation: Gcorge-A.Couture, rentier, 3160, chemin Ste-Foy, Jean Turgeon, commerçant, 704, du Chugcau, et Gérard Ber-liugucttc, ingénieur, 884, Rochelle, tous trois de Sainte-Foy, pour les objets suivants: Faire le commerce d'appareils de sécurité de toutes sortes, sous le nom de « Les Miroirs Directionnels inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.with a total capital stock of $60,000, divided into 600 common shares of $100 each.The head office of the company is nt Laurcntidcs, judicial district of Joliette.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 708-08 McMarjo Manufacturers Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Raymond Eric Parsons, 11 De Casson Road, D.Terence Dingle.501 I.ansdowne Avenue, and C.J.Michael Flavcll, 4043 Sherbrooke Street West, all three advocates, of Westmount, for the following purposes: To manufacture and deal in iron and steel and all other metals from the ore to the finished products thereof, under the name of \"McMarjo Manufacturers Limited\", with a total capital stock of S40.000, divided into 400 common shares of S100 each.The head office of the company is at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Prorince.24053-o 885-08 Mine Manufacturing Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Asher Kahn, advocate, 4S4 Duf-fcrin Road, Hampstead, Grace Blackctt, 5622 Sherbrooke, and Delphine Matthew, 3455 Aylmcr Street, the latter two secretaries, filles majeures, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of metals, under the name of \"Mine Manufacturing Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common sliares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 910-68 Les Miroirs Directionnels inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gcorges-A.Couture, annuitant, 3160 St.Foy Road, Jean Turgeon, trader, 704 du Chateau, and Gérard Berlinguette, engineer, 884 Rochettc, all three of St.Foy, for the following purposes: To carry on business dealing in all kinds of safety devices, under the name of \"Les Miroirs Directionnels inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at St.Foy, judicial district of Quebec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 810-68 Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.-'1053-o 810-68 2168 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100' année, n° U Mode Féminine inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour île mars 1968, constituant en corporation: Jacques Villeneuve, gérant, Angela Tremblay, ménagère, épouse séparée de biens dudit Jacques Villeneuve, tous deux de 302, Jollict, et William Tremblay, rentier, 256, Vaudrcuil, tous trois d'Arvida, pour les objets suivants: Faire le commerce dc marchandises sèches, sous le nom de « Mode Féminine inc.», avec un capital total dc $10.000, divisé cn 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est tt Arvida, district judiciaire de Chicoutimi.Le sous-secréhirc de la province, Raymond Douville.24053-o 707-68 Mode Féminine inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of March, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacques Villeneuve, manager, Angela Tremblay, housewife, wife separate as to property of said Jacques Villeneuve, both of 302 Jollict, and William Tremblay, annuitant, 256 Vaudrcuil, all three of Arvida, for the following purposes: To deal in dry goods, under the name of \"Mode Féminine inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Arvida, judicial district of Chicoutimi.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 707-68 Montreal Crane Rentals Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province n accordé des lettres patentes, cn date du 1er jour de mars 1968, constituant en corporation: Kenneth Swanson, 1217, 15e Avenue, Claude Parisien, 1839, 13e Avenue, tous deux marchands, et Jackson Harris, vendeur, 525, 26c avenue, tous trois de Pointeaux-Trembles, pour les objets suivants: Exercer le commerce et la location de grues de toutes descriptions et équipement connexes, sous le nom dc « Montreal Crane Rentals Company Limited », avec un capital total dc SI0.000, divisé cn 30,000 actions ordinaires de $1 chacune et 10,000 actions privilégiées dc SI chacune.Le siège social dc la compagnie est 1217, 15c Avenue, Pointc-aux-Tremblcs, district judiciaire de Montréal.Le sous-secretaire dc la province, Raymond Douville.24053 934-68 Morav Holding Corp.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour dc février 196S, constituant cn corporation: Lawrence L.Fligel, 5711, Edgemorc, Côte Saint-Luc, Norman S.Kcssner, 4555, Honavista, app.405, Montréal, tous deux avocats, Anne Brown, 5501, Adalbert, app.215, Côte Saint-Luc, et Daphne Saunderson, 322, Elm, Montréal, ces deux dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc placement, sous le nom dc « Morav Holding Corp.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053 721-63 Napiervillc Growers Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour dc février 1968, constituant en corporation: Herbert Clements Salmon, 3524, avenue Northcliff, Montréal, Norman Souaid, 511, rue Le Royer, Saint-Lambert, tous deux avocats, Maurice Trager, Montreal Crane Rentals Company Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, l>caring date by 1st day of March, 196S, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Kenneth Swanson, 1217, 15th Avenue, Claude Parisien, 1839, 13th Avenue, both merchants, ami Jackson Hirris, salesman, 525, 26th Avenue, all three of Pointc-aux-Trcm-blcs for the following purposes: To lease and ileal in cranes of every description and in allied equipment, under the name of \"Montreal Crane Rentals Company Limited\", with a total capital stock of $10.000, divided into 30,000 common shares of $1 each and 10,000 preferred shares of SI each.The head office of the company is at 1217, 15th Avenue, Pointe-aux-Trcmbles, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 934-68 Morav Holding Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 19th day of February, 196S, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Lawrence L.Fligcl, 5711^ Edge-more, Côte Saint-Luc, Norman S.Kcssncr, 4555 Bonavista, Apt.405, Montreal, both advocates, Anne Brown, 5501 Adalbert, Apt.215.Côte Saint-Luc, and Daphne Saunderson, 322 Elm, Montreal, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Morav Holding Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of S10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 721-68 Napiervillc Growers Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, beuring date the 13th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Herbert Clements Salmon, 3542 Northcliffe Avenue, Montreal, Norman Souaid, 511 Le Royer Street, Saint-Lambert, both advocates, Maurice Tragcr, office manager, 253 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.109, No.Ik 21G9 gérant de bureau, 253, Nord, avenue Westminster, Montréal-ouest, et Carol Labbé, secretaire, épouse séparée de biens de Robert Wiseman, 1, place Bellerive, app.706, Laval, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses catégories et ses spécialités, le commerce général de cultivateurs et emballeurs dc fruits et légumes, sous le nom de \u20ac Napierville Growers Inc.», avec un capital-actions divisé en 900 actions ordinaires sans valeur au pair et 791 actions privilégiées dc S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Napierville, district judiciaire d'iberville.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24053 699-68 Ncuvico Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé dc3 lettres patentes, en date du 8e jour dc février 1968, constituant en corporation: Yves Dubuc, menuisier.Jean-Claude Drolet, machiniste, et Jean-Paul Parent, électricien, tous trois de Neuville, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc placement et dc portefeuille, sous le nom dc « Ncuvico ltéc ».avec un capital total dc $40,000, divisé cn 3.000 actions ordinaires dc S10 cliacunc et cn 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est ù Neuville, district judiciaire dc Québec.Le sous-seerftaire dc la prorince, Raymond Douville.24053-o 5405-67 Westminster Avenue North, Montreal West, and Carol Labbé, secretary, wife contractually separate as to property of Robert Wiseman, 1 Place Bellerive, Apt.706, Laval, for the following purposes: To carry on in all its phases and branches the general business of growers and packers of fruits and vegetables, under the name of \"Napierville Growers Inc.\", with a capital stock divided into 900 common shares having no par value and 791 preferred sliares of $100 each.The head office of the company is at Napierville, judicial district of Iberville.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 699-68 Neuvico Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Yves Dubuc, carpenter, Jean-Claude Drolet.machinist, and Jean-Paul Parent, electrician, all three of Neuville, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"Ncuvico ltéc\", with a total capital stock of $40.000, divided into 3.000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at Neuville, judicial district of Quebec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Pro.incc.24053 5405-67 Ordre Martinistc et Synarcbique du Québec Avis est donné qu'en vertu dc la troisième partie de la Loi îles compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, cn date du 9c jour dc janvier 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Bobby Schermel, technicien.Willy Schermel, secrétaire, épouse dudit Bobby Schermel.tous deux de 2045, St-Louis.Saint-Laurent, Roger Laliberté, confiseur, 1959, boulevard Morgan, ('amy Van Der Pelen, traductrice, veuve non remariée «le Stcin Bugge, 4058, rue Ontario est, Thérèse St-Louis, avocate, fille majeure, 6440, 9cAvenue, Laurence Smith, ménagère, épouse dc Léger Gélinas, 6598, rue des Écorcs, Anna Rosa Zambrelli.traductrice, veuve dc Mario Zam-brelli.3994, rue Rachel, Ghislaine Gagné, chef de personnel, fille majeure.1010, Cherricr, app.1709, Gérald Caron.contrôleur, 6305,43e Avenue, tous sept dc Montréal, Y von Bouthillicr, commis, 898, avenue Victoria, Saint-Lambert, et Emile Desmarteaux, machiniste, 10939, rue Stc-Gcr-trude, Montréal-Nord, pour les objets suivants: Poursuivre les études mystiques telles qu'enseignées à travers le monde par le Martinismc, sous le nom de « Ordre Martinistc et Synarcbique du Québec ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $5,000.Le siège social de la corporation est 2045, rue St-Louis, Saint-Laurent,' district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24053-o 3845-07 Ordre Martinistc et Synarcbique du Québec Notice is given that under Part III of the Companies Act.letters patent, bearing date the 9th day of January, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, to incorporate a corporation without shore capital: Bobby Schermel, technician.Willy Schermel.secretary, wife of said Bobby Schermel, both of 2045 St-Louis, Saint-Laurent, Roger Laliberté, confectioner, 1959 Morgan Boulevard, Camy Van Dcr Pclcn, translator, unremarried widow of Stein Bugge, 4058 Ontario Street East.Thérèse St-Louis, advocate, spinster of the full age of majority, 0440, 9th Avenue, Laurence Smith, housewife, wife of Léger Gélinas, 0598 des Écorcs Street, Anna Rosa Zambrelli, translator, widow of Mario Zambrelli, 3994 Rachel Street, Gliislaiuc Gagné, personnel manager, spinster of the full age of majority, 1010 Cherricr, Apt.1709, Gerald Caron.comptroller.0305.43rd Avenue, all seven of Montreal, Y von Bouthillicr, clerk, 898 Victoria Avenue, Saint-Lambert, and Emile Desmarteaux, machinist, 10939 Stc-Gcrtrude Street, Montreal-North, for the following purposes: To pursue mystical studies such as taught across the world by Martinism, under the name of \"Ordre Martiniste et Synarcbique du Québec\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $5,000.The head office of the corporation is at 2045 St-Louis Street, Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 3845-67 2170 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 196S, 100- année, n' U P & G Amusements Inc.P & G Amusements Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies, l'administrateur Companies Act, letters patent, bearing date the du gouvernement dc la province a accordé des 12th day of March, 19GS, have been issued lettres patentes, en date usc séparée dc biens dudit Irwin Lerner, ces deux derniers dc 46, chemin Radcliffe, Montréal-ouest, pour les objets suivants: Exercer les affaires de nettoyeurs à sec et faire le commerce de vêtements, habillements, tissus marchandises, fournitures de maison, et articles de toutes sortes, sous le nom dc « Queen Mary Road Valet Service Inc.», avec un capital total de S 10,000, divisé cn 5,030 actions ordinaires de 81 chacune et 35,000 actions privilégiées dc SI chacune.Le siège social de la compagnie est 4942, chemin dc la Reine Marie, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.21053 800-68 Ralco Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de février 1968, constituant en corporation: Sidney Cutler, 5135.Bourrct, # 11.Jack Hoidman, 5320, Mac-Donald, tous deux avocats, de Montréal, et Norman Cohen, administrateur, 4853, Notre-Dame, Laval, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes dc produits, articles et marchandises, sous le nom dc < Ralco l orporation », avec un capital total de 810,030, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 cliacunc et 3.000 actions privilégiées dc S10 chucunc.Le siège social dc la compagnie est 901, rue lllcury, suite 314, Montréal, district judiciaire île Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.L'4053 923-68 Rayco Amusements Ltd.Amusements Rayco Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, cn date du 26e jour dc février 1968, constituant en corporation: Roger Rohillard, administrateur, 7436, Tanger, Brossard, Gérard Raynault, gérant, 55, Bcllechasse, Montréal, et Edwin J.Winston, avocat, 8250, chemin Macklc, Cote Saint-Luc, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, restaurants, boutiques, parcs d'attractions et de jeux et toutes sortes d'autres concessions, sous le nom de « Rayco Amusements Ltd.\u2014 Amusements Rayco Itée », avec un capital total de 810.000, divisé cn 3,033 actions ordinaires d'une valeur au pair dc $10 chacune et en 1,033 actions privilégiées d'une valeur ou pair de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est 55 est, rue Bellechassc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Queen Mary Road Valet Service Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorjioialing: Harold Brcndcr, dry cleaner, Bernicc Brendcr, housewife, wife separate as to property of the said Harold Brendcr, both of 807 Eiffel, Laval, Irwin Lerner, dry cleaner, and Eileen Lerner, housewife, wife separate as to property of the said Irwin Lerner, the latter two of 46 Radcliffe Road, Montreal West, for the following purposes: To carry on business as cleaners and to deal in clothing, garments, fabrics, goods, household furnishings, materiols and articles of every kind, under the name of \"Queen Mary Road Valet Service Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 5.000 common shares of $1 each and 35,000 preferred shores of 81 each.The head office of the company is at 4942 Queen Mary Road, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 800-68 Ralco Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Sidney Culler, 5135Bourrct, # 11, Jack Boidman, 5320 MacDonald, both advocates, of Montreal, and Norman Cohen, executive, 4853 Notre-Dame, Laval, for the following purposes: To deal in all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"Ralco Corporation\", with a total capita! stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shores of $10 each.The head office of the company is at 901 Bleury Street, suite 314, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 923-68 Rayco Amusements Ltd.Amusements Rayco Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roger Robillard, administrator, 7436 Tanger, Brossard, Gérard Raynault, manager, 55 Bellechasse, Montreal, and Edwin J.Winston, advocate, 8250 Mackle Road, Côte Saint-Luc, for the following purposes: To operate hotels, restaurants, boutiques, amusement rides and any and all other concessions, under the name of \"Rayco Aniusements Ltd.\u2014 Amusements Rayco ltéc\", with a total capital stock of $40,033.divided into 3,000 common shares of a par value of $10 each and 1,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at 55 Bellechasse Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 862-68 Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24053 862-68 2174 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, G avril 19G8, 100' année, n° H Regent Construction (1968) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I/ii des compagnies, le lieutenant-gouverneur île la province a accordé des lettres patentes, en date du 19c jour de janvier 1968, constituant cn corporation: Samuel Omit, 4, Surrey Gardens, C.Ralph Lipper, 4350, ouest, rue Sherbrooke, tous «'.eux dc Westmount, et Bernard Reis, 213, Finehlcy, Humpstcad, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer un commerce (('entrepreneurs généraux, sous le nom de « Regent Construction (1968) Ltd.», avec un capital total de 810.003, divisé cn 100 actions ordinaires de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie est 2521.rue Charland, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-seertiaire de la province, Raymond Douville.24053 286-68 Reliable Button & Buckle Corp.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province n accordé «les lettres patentes, cn date «lu 9e jour de février 1968.constituant en corporation: Lawrence L.Fligcl, avocat, 5711, Edgemorc, Anne Brown, secrétaire, célibataire, 5501, Adalbert, app.215, tous «leux de Côte Saint-Luc, et Norman S.Kcssncr, avocat, 4555, Bonavista, app.405, Montréal, pour les objets suivants: Acheter, vendre et distribuer des boutons, boucles et autres articles semblables, sous le nom dc « Reliable Button & Buckle Corp.».avec un capital total de $40.000, divise* cn 10.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège socinl dc la compagnie est ù Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-sccrflaire dc la province, Raymond Douville.24053 629-68 Restaurant Apollo inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour dc février 1968.constituant cn corporation: Peter Vannakis, Gerry Vannakis, tous «leux dc 6807.Montée St-Michcl.Saint-Michel.Spiros Zafiratos.tous trois restaurateurs, et Spiros Dimos.mécanicien, ces deux derniers de 5572, Les Bccqucts, Saint-Léoiurd.pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom dc « Restaurant Apollo inc.».avec un capital tolal dc $30.000, divisé cn 1,000 actions ordinaires, dc S10 chacune et 2,000 actions privilégiées dc $10 chneunc.Le siège social dc la compagnie est 0514, rue St-IIubert, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24053 914-68 Rex Auto Sales Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, cn date du 8e jour dc février 1968, constituant en corporation: Edward Korn, Regent Construction (1968) Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of January, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Samuel Chair, 4 Surrey Gardens, C.Ralph Upper, 4350 Sherbrooke West Street, but 11 of Westmount, and Bernard Rcis, 213 Finehlcy, Hampstead, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as general contractors, under the name of \"Regent Construction (1068) Ltd.\", with n totul capital stock of S10.000, \u2022 livide 1 into 100 common shares of $100 each.The head office of the company is at 2521 Charland Street, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 286-68 Reliable Button & Buckle Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing «Intc the 9th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Lawrence L.Fligcl, advocate, 5711 Edgemorc, Anne Brown, sccretarv, spinster, 5501 Adalbert, Apt.215, both of Côte Siint-Luc, and Norman S.Kcssncr, advocate, 4555 Bonavista, Apt.405, Montreal, for the following purposes: To buy, sell and distribute buttons, buckles and other similar articles, under the name of \"Reliable Button & Buckle Corp.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 10.000 common shares of a par value of $1 each and 300 preferred shares of a par value of S100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 629-6S Restaurant Apollo inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 28lh day of February.1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Peter Yanrnkis.Gerry Vannakis.both of 0807 Montée St-Michcl, Saint-Michel.Spiros Zafiratos, all three restaurateurs, and Spiros Dimos, mechanic, the latter two of 5572 Les Beequets, Saint-Léonard, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Restaurant Apollo inc.\", with a total capital stock of $30.000.divided into 1.00(1 common sliares of $10 each and 2,000 preferred sliares of $10 each.The head office of the company is at 0514 St.Hubert Street, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 914-68 Rex Auto Sales Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th «lay of February, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Edward Korn, executive, 148 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6'.1968, Vol.100, No.11 2175 administrateur, 148, Butternut Crescent, Dol-lard-des-Ormeaux, Ludovick U.Kurys, gérant, 0138, rue Centrale, LaSalle, et Emmanuel Major, gérant des ventes, 75 du Parc, Laval, pour les objets suivants: Exploiter et gérer des garages et exercer le commerce de toutes sortes d'automobiles, caillions, tracteurs, machinerie aratoire et instruments, voitures, leurs pièces et accessoires, sous le nom de « Rex Auto Sales Inc.».avec un capital total dc 840,000, divisé cn 10.000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées dc 810 cliacunc.Le siège social dc la compagnie est 237, avenue Van Hornc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-sccrCtairc de la province, Raymond Douville.211)53 583-68 Rideau Stainless Products Ltd.Les Produits inoxydables Rideau Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, cn date du 14e jour de février 1968, constituant en corporation: Maurice B.Schwartz, homme d'affaires, Clara Schwartz, ménagère, épouse séparée de biens dudit Maurice B.Schwartz, et Allan Schwartz, homme d'affaires, tous trois dc 146, Sherwood Drive, Ottawa, dc la province d'Ontario, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de toutes sortes dc métaux, sous le nom dc « Rideau Stainless Products Ltd.\u2014 Les Produits inoxydables Rideau Itée», avec un capital divisé en 5.000 actions ordinaires sans valeur au pair et en 35.000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Hull, district judiciaire dc Hull.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.21053 603-68 Road Air Services Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, cn date du 27e jour dc février 1968, constituant en corporation: Jean Savard, 4351, Draper, Montréal, Raymond Crevier, 497, chemin Stc-Catherinc, Outrcmont, et Pierre Legrand, 1135) Cap Éternité, Laval, tous trois avocats, |xiur les objets suivants: Exercer un commerce général de camionnage et du transport d'effets, bagages, colis et marchandises, sous le nom de « Road Air Services Ltd.-., avec un capital total de $40,000.divisé en 40,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 9198, Boivin, LaSalle, district judiciaire dc Montréal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.21053 816-68 Roy, Tétrcault inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de janvier 1968, constituant en corporation: Gérard Tétrcault, artiste publicitaire, Jeanne Savard, infirmière, c|»use dudit Gérard Tétreault, tous deux de 8675, Acterna, Saint-Léonard, Raymond Roy, artiste Butternut Crescent, Dollard-des-Ormcaux, Ludovick R.Kurys, manager, 9438 Central Street, LaSalle, and Emmanuel Major, sales manager, 75 Park, Laval, for the following purposes: To operate and manage garages and to manufacture and deal in all kinds of automobiles, trucks, tractors, farm macliinery and implements, cars and their parts and accessories, under the name of \"Rex Auto Sales Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 237 Van Hornc Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 583-68 Rideau Stainless Products Ltd.Les Produits inoxydables Rideau Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating; Maurice B.Schwartz, businessman, Clara Schwartz, housewife, wife separate as to property of the said Mam ice B.Schwartz, and Allan Schwartz, businessman, all three of 146 Sherwood Drive, Ottawa, of the Province of Ontario, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of metals, under the name of \"Rideau Stainless Products Ltd.\u2014 Les Produits inoxydables Rideau Itée\", with a capital stock divided into 5,000 common shares without par value and 35,000 preferred sliares of the par value of $1 each.The head office of the company is at Hull, judicial district of Hull.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 603-68 Road Air Services Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean Savard, 4351 Draper, Montreal, Raymond Crevier, 497 Ste-Catherine Road, Outremont, and Pierre Legrand, 1435 Cap Éternité, Laval, all three advocates, for the following purposes: To carry on generally the business of trucking and transporting goods, wares, luggage, parcejs and merchandise, under the name of \"Road Air Services Ltd.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 40,000 common shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at 9198 Boivin, LaSalle, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 816-68 Roy, Tétrcault inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gérard Tétreault, publicity artist, Jeanne Savard, nurse, wife of said Gérard Tétreault, both of 8675 Aeterna, Saint-Léonard, Raymond Roy, publicity artist, and Monique 2176 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100' année, n' U publicitaire, et Monique Normand, ménagère, épouse dudit Raymond Roy, ces deux derniers de 2211, Perse, Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs et conseillers en publicité, sous le nom de « Roy, Tétreault inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $25 chacune et en 1,200 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social dc la compagnie est 5315, rue Jarry est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 248-68 S.O.M.Corporation La Corporation S.O.M.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la I -> »î des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29c jour de février 1968, constituant cn corporation: Harvey M.Cooper-stonc, 1448, Beverley Crescent, Laval, Maximi-lien Polak.7897, Wavell, Côte Saint-Luc, tous deux avocats, Jovitte Dmuchalsky, 581, Ladouceur, Laval, et Francine Végiard, 3465, Hutchison, Montréal, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de construction et d'immeubles, sous le nom de < S.O.M.Corporation ¦\u2014 La Corporation S.O.M.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires «le $10 chacune et 2,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 6338, avenue Victoria, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053 908-68 Saint-Onge électronique inc.Avis est «lonné qu'en vertu dc la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de février 1968, constituant en corporation: Paul-B.St-Onge.industriel, 2990, Matapédia, Sainte-Foy, Dyanc Gauthier, secrétaire, fille majeure, et Charles-E.Poirier, notaire, ces «leux derniers de 4032, Parc Lafontainc.Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme électriciens et faire le commerce dc toutes sortes d'accessoires pour fins domestiques ou commerciales, sous le nom de « Saint-Onge électronique inc.», avec un capital total dc $40.000.divisé cn 200 actions ordinaires de $10 chacune et cn 3,800 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1355, chemin Ste-Foy, Québec, district judiciaire de Québec.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 586-68 Salaison Turcot inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accortlé des lettres patentes, en date du 12e jour dc février 1968, constituant cn corporation: Jean-Paul Turcotte, boucher.Edna Aubin, ménagère, épouse dudit Jean-Paul Turcotte, tous deux de 194, St-Albert, Chicoutimi-Nord, et Robert Lalancettc, commerçant, 27, Notre-Dame, Saint-Jcan-Eudcs, pour les objets suivants: Normand, housewife, wife of said Raymond Roy, the latter two of 2211 Perse, Laval, for the following purposes: To carry on business as publicity counsellors and contractors, under the name of \"Roy, Tétrcault inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 400 common shares of $25 each and into 1,200 preferred shares of $25 each.The head office of the company is at 5315 Jarry Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 248-68 S.O.M.Corporation La Corporation S.O.M.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 29th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Harvey M.Coopcrstone, 1448 Beverlv Crescent, I, réduisant son capital dc $10,000 A $20,000, le capital-actions annulé étant divisé en 150 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Ia sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24053-o 15623-61 \u2014 1411/50 the Province to \"Safety Glove and Clothing Inc.\", reducing its capital stock from $40,000 to $25,000, the cancelled share capital being divided into 150 preferred shares of a par value of $100 each.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 15023-61 \u2014 1411/50 Simtel Incorporated Simtcl incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes supplémentaires cn date du 13e jour dc février 1968, A la compagnie « Simtel Incorporated\u2014 Simtel incorporée», 1° diminuant son capital de $508,000 à $55,450, le capital-actions annulé étant divisé cn 3,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc $1 chacune, 3,950 actions catégorie « A » d'une valeur au pair dc $1 chacune et 4,456 actions privilégiées d'une vuleur nu pair de $100 chacune; 2° subdivisant ses 511 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune en 54,400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune; 3° convertissant ses 50 actions catégorie « A » d'une valeur au puir dc $1 cliacune en 50 actions ordinaires d'une valeur au pair dc $1 chacune; 4\" convertissant ses 53,400 actions privilégiées d'une valeur au pair dc $1 chacune en 53,400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune; 5° consolidant ses 54,450 actions ordinaires d'une valeur au pair dc $1 chacune cn 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc $54.45 chacune; 6° changeant ses 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc $54.45 chacune en 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair; 7° amendant les privilèges et restrictions attachés A ses actions privilégiées.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053 1283-05\u2014 1410/62 Simtcl Incorporated Simtel incorporée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, hearing date the 13th day of February, 196s, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Simtel Incorporated \u2014 Simtel incorporée\", 1.reducing its capital from $508,0011 to $55,450, the capital stock annulled being divided into 3,000 common shares of the par value of $1 each, 3,950 class \"A\" shares of the par value of $1 each and 4,456 preferred shares of the par value of $100 each; 2.subdividing its 544 preferred sliares of the par value of $100 each into 54,400 preferred shares of the par value of $1 each; 3.converting its 50 class \"A\" shares of the par value of $1 each into 50 common shares of the par value of $1 each; 4.converting its 53,400 preferred shares of the par value of $1 each into 53,400 common sliares of the par value of SI each; 5.consolidating its 54,450 common shares of the par value of $1 each into 1,000 common shares of the par value of $54.45 each; 6.changing its 1,000 common shares of the par value of $54.45 each into 1,000 common shares without nominal or par value; 7.modifying the privileges and restrictions attached to its preferred shares.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 1283-05 \u2014 1410/02 La Société Chimique Valco Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 26c jour de février 1968, A la compagnie « Marais et Labric Presto inc.», constituée par lettres patentes en date du 2Se jour de septembre 1967, changeant son nom en celui de « La Société Chimique Valco Itée».Lt soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053-o 4170-67\u2014 1411/57 La Société Chimique Valco Itée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of February, 196S have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Marois et Labrie Presto inc.\", incorporated by letters patent dated the 281 li day of September, 1967, changing its name to that of \"La Société Chimique Valco Itée\".Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 4170-67 \u2014 1411/57 La Société Lancel inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour de février 1968, A la compagnie « Les Entreprises Lancel inc.», constituée par lettres patentes en date du 6e jour de mars 1967, changeant son nom en celui de « La Société Lancel inc.».La Société Lancel inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of February, 196$.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Les Entreprises Lancel inc.\", incorporated by letters patent dated the day of March, 1967, changing its name to that of \"La Société Lancel inc.\".Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville, Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.24053-o 435-67 \u2014 1410/127 24053 435-67\u20141410/127 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.U 2198 la Société Manufacturière de Quincaillerie Montréal Itée The Montreal Hardware Manufacturing Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi tics compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 6e jour de février 1968, ù la compagnie « The Montreal Hardware Manufacturing Co.», constituée par lettres patentes en date du 29e jour dc mars 1 s!)S, changeant son nom en celui «le « La Société Manufacturière dc Quincaillerie Montréal Itée \u2014 The Montreal Hardware Manufacturing Company Ltd.».Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.21053-o 1048-98\u2014 1410/128 Studio 10 Shoes Ltd.Chaussures Studio 10 ltéc Avis est donné qu'en vertu de la première partie île la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires cn date du 27c jour de février 1968, ù la compagnie «Studio 7 Shoes Ltd.\u2014 Chaussures Studio 7 Itée», constituée par lettres patentes en date du 28c jour de décembre 1967, changeant son nom cn celui de \u2022 Studio 10 Shoes Ltd.\u2014 Chaussure, Studio 10 Itée».Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.21053 5417-67\u2014 1410/129 La Société Manufacturière dc Quincaillerie Montréal Itée The Montreal Hardware Manufacturing Company Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 6tli day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"The Montreal Hardware Manufacturing Co.\", incorporated by letters patent dated the 29th day of March, 1898, changing its name to that of \"La Société Manufacturière de Quincaillerie Montréal Itée \u2014 The Montreal Hardware Manufacturing Company Ltd.\".Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 1048-98 \u20141410/128 Studio 10 Shoes Ltd.Chaussures Studio 10 Itée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 27th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Studio 7 Shoes Ltd.\u2014 Cliaussu-res Studio 7 Itée\", incorporated by letters patent dated the 28th day of December, 1967, changing its name to that of \"Studio 10 Shoes Ltd.\u2014 Chaussures Studio 10 Itée\".Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 5417-67 \u20141410/129 Textllco inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29c jour de février 1908, ù In compagnie « Industrial Sanitary Products Limited \u2014 Les Produits Sanitaires In-dustriela limitée », constituée par lettres patentes en date du 6e jour de mars 1947, changeant son nom en celui dc « Tcxtilco inc.».Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24053* 2470-47\u2014 1410/130 Textilco inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent bearing date the 29th day of February, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Industrial Sanitary Products Limited \u2014 Les Produits Sanitaires Industriels, limitée\", incorporated by letters patent dated 6th day of March, 1947, changing its name to tliat of \"Textilco inc.\".Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053 2470-47 \u2014 1410/130 Hôpital Notre-Dame-du-Lac Erratum Hans l'avis publié dans le numéro 41 de la Gazette officielle de Québec, du 14 octobre 1967, à la page 6025, sous le titre ci-haut mentionné, au lieu dc «Hôpital Notrc-Dame-du-Retour», il faut lire «Hôpital Notre-Dame-du-Détour».24053m Hôpital Notre-Dame-du-Lac Erratum In the notice published in number 41 of the Quebec Official Gazette, of October 14, 1967, on page 6025, under the title hereabove mentioned, instead of \"Hôpital Notre-Damc-du-Retour\", one must read \"Hôpital Notre-Dame-du-Détour\".24053 Avis divers Miscellaneous Notices Manfred Klaus Bcjcck H a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 726, du 20 mars 1968, d'clfectuer le changement de nom de Manfred Klaus Sekinger cn celui de Manfred Klaus Bejcek.Québec, 28 mars 1968.Le sous-seerftaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Manfred Klauss Bejcek The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by drecee number 726, dated March 20, 1968, to change the name of Manfred Klaus Sekinger to that of Manfred Klaus Bejcek.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Sssistant Secretary of the Province. 2194 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, G avril 19G8, 100' année, n\" IL Conseil Mgr.Ross No 3261 des Chevaliers de Colomb de Chandler inc.Le « Conseil Mgr Ross No 3261 des Chevaliers de Colomb de Chandler inc.», Chandler, P.Q., donne avis, par les présentes, qu'il possède son siège social à l'adresse susmentionnée et qu'il se prévaut des dispositions de la Loi concernant les Chevaliers dc Colomb dc la province de Québec (1-2 Elizabeth II, cliap.134) a partir du 30 octobre 1967.Chandler.8 mars 1968.Le grand chevalier, Guy Émono.Le secrétaire-archiviste, Romlalu Boutin.24054-u 7-68 Joseph Grégoire Philippe André Caulet Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 721, du 20 mars 1968, d'effectuer le changement de nom de Joseph Grégoire Philippe André Culet en celui de Joseph Grégoire Philippe André Caulet.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Joseph Jean-Baptiste Réjean Caulet Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 722, du 20 mars 1968, d'effectuer le changement de nom de Joseph Jean-Baptiste Réjean Culet en celui de Joseph Jean-Baptiste Réjean Caulet.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Dem Condax Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 714, du 20 mars 1968.d'effectuer le changement de nom de Dcmetre Condaxakis en celui de Dem Condax.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Joseph Armand Léoncl Bernard de Brienne Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 712, du 20 mars 1968, d'effectuer le changement de nom de Joseph Armand Léoncl de Brienne en celui de Joseph Armand Léonel Bernard dc Brienne.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Michael Erlich Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 716, du 20 mars 1968, d'ffectuer le changement de nom de Mendel Erlich cn celui de Michael Erlich.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Joseph Roger Claude Fournier Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 727, du 20 mars 1968.d'effectuer le changement de nom de Joseph Roger Claude en celui de Joseph Roger Claude Fournier.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Council Msgr.Ross No.3261 of the Knights of Columbus of Chandler Inc.\"Council Msgr Ross No.3261 of the Knights of Columbus of Chandler Inc.\", Chandler, P.Q.hereby gives notice that its head office is located at the above mentioned address and that it is availing itself of the provisions of the Act respecting the Knights of Colombus of the province of Quebec (1-2 Elizabeth II, chap.134, sec.2a) as from October 30, 1967.Chandler, March 8, 1968.Guy Émond, Grand Knight.Romuald Boutin, Becorder.24054-o 7-68 Joseph Grégoire Philippe André Caulet The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 721, dated March 20, 1968, to change the name of Joseph Grégoire Philippe André Culet to that of Joseph Grégoire Philippe André Caulet.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province.Joseph Jean-Baptiste Réjean Caulet The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 722, dated March 20, 1968, to change the name of Joseph Jean-Baptiste Réjean Culet to that of Joseph Jean-Baptiste Réjean Caulet.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province.Dem Condax The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 714, dated March 20, 1968, to change the name of Demetre Condaxakis to that of Dem Condax.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province.Joseph Armand Léonel Bernard de Brienne The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 712, dated March 20, 1968, to change the name of Joseph Armand Léonel de Brienne to that of Joseph Armand Léonel Bernard de Brienne.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province.Michael Erlich The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 716, dated March 20.1968, to change the name of Mendel Erlich to that of Michael Erlich.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province.Joseph Roger Claude Fournier The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 727, dated March 20.1968, to change the name of Joseph Roger Claude to that of Joseph Roger Claude Fournier.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.11 2195 Paul Hart Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 718, du 20 mars 1968, d'effectuer le changement de nom de Pincus Herschko-vitz cn celui de Paul Hart.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Murray Krane Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 717, du 20 mars 1968, d'effectuer le changement de nom de Murray Krasovitsky en celui de Murray Krane.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Dominic Mastro Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 723, du 20 mars 1968, d'effectuer le changement de nom de Dominico Mastromonaco en celui de Dominic Mastro.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Maurice Saleh Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 725, du 20 mars 1968, d'effectuer le changement de nom de Moshe Saleh en celui de Maurice Saleh.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 21053-o Raymond Douville.Charles Ivan Shelley Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 713, du 20 mars 1968, d'effectuer le changement de nom de Karoly Ivan Sellci en celui de Charles Ivan Shelley.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Robert Steiner Sherwood Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 719, du 20 mars 1968, d'effectuer le changement de nom de Robert Otto Krvin Steiner en celui de Robert Steiner Sher- ft'nod.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Max Smart Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 720, du 20 mars 1968, d'effectuer le changement de nom de Max Selimerer en celui de Max Smart.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 21053-o Raymond Douville.Gustav Charles Wilson Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 715, du 20 mars 1968, d'effectuer le changement de nom de Gustav Charles Ryner en celui de Gustav Charles Wilson.Québec, 28 mars 1968.Le soussecrétaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Paul Hart The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 718, dated March 20, 1968, to change the name of Pincus Herschkovitz to that of Paul Hart.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province.Murray Krane The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 717, dated March 20, 1968, to effect the change of nameof Murray Krasovitsky into that of Murray Krane.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24953 Assistant Secretary of the Province.Dominic Mastro The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 723, dated March 20, 1968, to effect the charge of name of Dominico Mastromonaco into that of Dominic Mastro.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province.Maurice Saleh The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 725, dated March 20, 1968, to effect the change of name of Moshe Saleh into that of Maurice Saleh.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province.Charles Ivan Shelley The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 713, dated March 20, 1968, to effect the change of name of Karoly Yvan Sellei into that of Charles Ivan Shelley.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistattt Secretary of the Province.Robert Steiner Sherwood The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 719, dated March 20, 1968, to effect the change of name of Robert Otto Ervin Steiner into that of Robert Steiner Sherwood.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province.Max Smart The Lieutenant-Governor in Council, by decree number 720, dated March 20, 1968, has been pleased to effect the change of name of Max Schmerer into that of Max Smart.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province.Gustav Charles Wilson The lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 715, dated March 20, 1968, to effect the change of name of Gustav Charles Ryner into that of Gustav Charles Wilson.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province. 2196 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100' année, n\" U Sam Wong Il n plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 724, du 20 mars 1968, d'effectuer le changement de nom de San Lin Seto en celui dc Sam Wong.Québec, 28 mars 1968.Le sous-secretaire de la province, 24053-o Raymond Douville.Ville de Saint-Hubert Avis public est par les présentés donné, que la « Ville dc Saint-Hubert » présentera au lieutenant-gouverneur en conseil, une requête aux fins d'obtenir l'émission dc lettres patentes pour remplacer par le paragraphe a) dc l'article 429 «le la Loi des cités et villes, l'article 24 de sa charte (6-7 Elizabeth II, cliapitre 112) concernant principalement l'acquisition par la municipalité dc rues ou ruelles ouvertes au public depuis au moins dix (10) ans.Donné sous mon seing, il Saint-Hubert, ce 19c jour dc mars 1968.Le greffier, 24055-o Yvan Grenier, Corporation des Techniciens Professionnels de la province dc Québec (Erratum) Veuillez noter qu'A la page 1177 de la Gazette officielle du 17 février 1968, à l'article 24, les derniers mots du paragraphe devraient être « 1 mni » au lieu de « 1 mars ».24053-o Sam Wong The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 724, dated March 20, 1968, to effect the change of name of San-Lin Seto into that of Sam Wong.Quebec, March 28, 1968.Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province.Town of Saint-Hubert Public notice is hereby given, that the \"Town of Saint-Hubert\" will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council for the issue of letters patent to replace by paragraph (a) of section 429 of the Cities and Towns Act section 24 of its charter (6-7 Elizabeth II.chapter 112) concerning particularly the acquisition by the municipality of the streets or lanes opened to the public for ten (10) years or more.(Jiven under my hand, at Saint-Hubert, this 19th day of March 1968.Yvan Giieniek, 24055-o City Clerk.Corporation of Professional Technicians of the Province of Quebec (Erratum) Please note that on page 1177 of the Official Gazette of February 17, 1968, section 24.the last words of the said paragraph should be \"May 1st\" instead of \"March 1st\".24053-o Compagnies autorisées à faire des affaires La Compagnie foncière du Manitoba (1967) limitée Avis est donné qu'en vertu dc la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « La Compagnie Foncière du Manitoba (1967), limitée», a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Marc H.Dhavernas, 1420, ouest, rue Sherbrooke, suite 850, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi A suite 850, 1420, ouest, rue Sherbrooke, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24053 10-68\u20141413/124 MTB Corporation Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « MTB Corporation», a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins dc recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Michel P.Souvay, 2955, boulevard Edouard Montpetit, app.7, Montréal.Le bureau principal dc la compagnie dans la Rrovince est établi A 5310, avenue du Parc, Iontréal, district judiciaire de Montréal.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24053 19-68\u20141413/69 Companies Licensed to do Business La Compagnie Foncière du Manitoba (1967), limitée Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"La Compagnie Foncière du Manitoba (1967), limitée\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Marc II.Dhavernas, of 1420 Sherbrooke Street West, suite 850, Montreal.The principal office of the company in the Province is at suite 850, 1420 Sherbrooke Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.24053-o 10-68 \u20141413/124 MTB Corporation Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"MTB Corporation\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Michel P.Souvay, of 2955 Edouard Montpetit Boulevard, Apt.7, Montreal.The principal office of the company in the Province is at 5310 Park Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 19-68 \u20141413/69 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.Ik 2197 T.S.Simms & Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « T.S.Simms & Co.Limited », a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Philippe Roland Robitaille, 3470, est, boulevard St-Joseph, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 3470, est boulevard St-.loseph, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.\u202224053 3-68 \u2014 1413/1 T.S.Simms & Co.Limited Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, 'T.S.Simms & Co.Limited\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Philippe Roland Robitaille, 3470 St.Joseph Boulevard East, Montreal.The principal office of the company in the Province is at 3470 St.Joseph Boulevard East, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24053-o 3-68 -1413/1 Sièges sociaux Head Offices Chateau Corp.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « Chateau Corp.», constituée en corporation par letters patentes le 26ième jour de janvier, 1905, et ayant son siège social en la ville de Montréal, à 4141 rue Sherbrooke, ouest, suite 300, cn les cité et district de Montréal, le 20ièmc jour de juin, 1967.A compter de la date dc cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, le 26ième jour de mars, 1968.(Sceau) Le président, Mark Suapiro.24088-o 372-65 Chateau Corp.Notice is hereby given that \"Chateau Corp\", incorporated by letters patent on the 26th day of January, 1965, and having its head office in the city of Montreal, at 5485 Sherbrooke St.West, has moved it to 4141 Shrebrooke St.West, Suite 300, in the City and Dictrist of Montreal on the 20th day of June, 1967.From and after this date, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 26th day of March, 1968.Mark Shapiro, (Seal) President.24088-o 372-65 Compagnie Générale de Placement, limitée General Investment Company, Limited Avis est par les présentes donné que « Compagnie Général de Placement, limitée \u2014 General Investment Company, Limited », constituée le Oième jour de novembre 1957 et ayant son bureau chef à 221 ouest, rue St-Jacques, Montréal, où son bureau chef était situé jusqu'à ce jour a drmanagé à 360 ouest, rue St-Jacques, Montréal el à compter de la date de cet avis, cedit bureau sera considéré comme étant le bureau chef de la compagnie.Montréal, 28 février 1968.Le secrétaire, Lorraine Coté.21067 13444-57 J.R.Dionnc inc.Avis est donné que la compagnie « J.R.Dionne inc.», constituée en corporation sous la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes émises par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, cn date du 12e jour de décembre 1967, a établi son bureau au numéro ô'i.de la rue Rouville, ville de Baic-Comeau, comté de Saguenay.À compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Baic-Comeau, ce 17e jour de mars 19G8.Le président, Jean Roch Dionne.-'\u20221U72-0 4978-67 Compagnie Générale dc Placement, limitée General Investment Company, Limited Notice is hereby given that \"Compagnie Générale déplacement, limitée \u2014 General Investment Company, Limited\", incorporated on the 6th day of November, 1957, and having its head office at 221 St.James Street West, Montreal, where its head office was situated until today, has moved to 360 St.James Street West, Montreal, and from and after the date of this notice, the said office will be considered as being the head office of the company.Montreal, February 28, 1968.Lorraine Coté, Secretary.24067 13444-57 J.R.Dionne inc.Notice is hereby given tliat the \"J.R.Dionuc inc.\", company incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patents bearing date the 12th day of December 1967, issued by the Lieusenant-Governor of the province of Quebec, has established its office at number 53, Rouville Street, in the city of Baie-Comeau.county of Saguenay.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Baic-Comeau, this 17th day of March, 1968.Jean Rocii Dionne, President.24072-o 4978-67 2198 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100' année, n° U Re-Hec Inc.Avis est donné que la compagnie « Re-Hec Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 2 février 1968 et ayant son siège social dans la cité de Bouchervillc a établi son bureau au numéro 16 dc la rue DcNiverville.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 22e jour de mars, 1968.Ia secrétaire-trésorier, 24073-o Hector Tiiessereault.Vallée des Sables inc.Avis est donné que la compagnie < Vallée des Sables inc.», constituée cn corporation selon la première partie de la Loi des compagnies S.R.Q.1964.chapitre 271.en date du 6 février 1968, a établi son bureau principal à Val Limoges, Mont-Laurier, district de Labclle.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 21c jour dc mars 1968.Le président, Roger Taii.lon.24074-o 450-68 Re-Hec Inc.Notice is hereby given that the \"Re-Hec Inc.\", company, incorporated by letters patent on the February 2, 1968 and having its head office in Bouchcrville has established its office at number 16 DeNivervillc Street.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 22nd day of March, 1968.Hector Tiiessereault, 24073-o Secretary-Treasurer.Vallée des Sables inc.Notice is hereby given tliat \"Vallée des Sables inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act.R.S.Q., 1964, chapter 271, on Fe-bruary 6, 1968, has established its principal business place at Val Limoges, Mont-Lauricr.district of I.libelle.From and after the dale of the present notice, the said olficc is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 21st day of March, 1968.Roger Taillon, President.24074 450-68 Institut des Sciences Commerciales Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « Institut des Sciences Commerciales», constituée en corporation en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies (Québec), par letters patentes émises le 14 février 1968, a établi son bureau principal au au numéro 210 ouest, rue Notre-Dame, Montréal, district de Montréal, province de Québec.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 25e jour de mars 1968.Le secrétaire, Myrto Brasseur.24089-o 272-68 Le Mac Mobile Feed Unit Ltd.Meunerie Mobile Le Mac ltéc Avis est par les présentes donné que la compagnie « Le Mac Mobile Feed Unit Ltd.\u2014 Meunerie Mobile Le Mac Itée», constituée en corporation par lettres patentes le 26 janvier 1968, a établi son bureau et siège social à Dunham, comté de Missisquoi, district de Bedford, province de Québec.À compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Dunham, le 14 mars 1968.Le président, Gordon Gutiirie.24090-e 4995-67 Milton-Ste.Famille Corporation Avis est donné que la compagnie « Milton-Ste.Famille Corporation », a déménagé son siège social de 548, rue Saint-Roch, Saint-Laurent, à 4770, avenue Kent, bureau 214, Montréal.Le secrétaire-trésorier, I.Farber.24127 5430-65 Institut des Sciences Commerciales Notice is hereby given that \"Institut des Sciences Commerciales\", incorporated under Part III of the Companies Act (Quebec), by letters patent dated February 14, 1968, has established its head office at number 210 Notre-Dame Street West, Montreal, district of Montreal, Province of Quebec.From and after the date of this notice, the said office will be considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 25th day of March, 1968.Myrto Brasseur, Secretary.24089 272-68 Le Mac Mobile Feed Unit Ltd.Meunerie Mobile Le Mac liée Notice is hereby given thay \"Le Mac Mobile Feed Unit Ltd.\u2014 Meunerie Mobile Le Mac Itée\", company incorporated by letters patent bearing the date of January 26, 1968, has established its office at Dunham, county of Missisquoi, district of Bedford, Province of Quebec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dunham, March 14, 1968.Gordon Guthrie, President.24090-o 4995-67 Milton-Ste.Famille Corporation Notice is given that \"Milton-Ste.Famille Corporation\", has transferred its head office from 548 St.Roch Street, St.Laurent, to 4770 Kent Avenue, Suite 214, Montreal.I.Farber, Secretary- Treasurer.24127-0 5430-65 GAZETTE OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.H 2199 Peinture & Décor (St.Jean) Itée Avis est donné que la compagnie « Peinture & Décor (St.Jean) Itée», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes accordées le 19c jour dc février 196S, a établi son siège social en la cité de St-Jcan, au numéro civique 159, rue St-Jncqucs.À compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 21e jour de mars 1968.(Sceau) 21091 Le secrétaire, Joseph Sobie.648-68 Quemat inc.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Quemat inc.», constituée cn corporation dans la province de Québec, par lettres patentes en date du 16 février 1968 et ayant son siège social A Bouchcrville, district judiciaire dc Montréal, a établi son bureau principal au numéro 111 rue de Lauzon, Bouchcrville, district dc Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 27e jour de mars 1968.Le président, Jean-Claude Leroux.21092-o 751-68 Rycade inc.Avis est donné que la compagnie « Rycade inc.», constituée cn corporation dans la province de Québec, par lettres patentes accordées en vertu des dispositions de la Loi des compagnies, cn date du 30 janvier 1968.et ayant son bureau principal dans les cité et district de Montréal, province de Québec, a établi son bureau au numéro 612 ouest, rue St-Jacques, Montreal, ijué., a/s Mes Geoffrion & Prud'homme, attention : Me Raymond G.Décary, c.r. compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Signé à Montréal, ce cinquième jour du mois de février 1968.Le secrétaire, Raymond Jean Décary.24093-o 415-68 Peinture & Décor (St.Jean) Itée Notice is hereby given that \"Peinture & Décor (St Jean) Itée\", incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patent granted on the 19th day of February, 1968, has established its head office in the city of St.Jean at civic number 159 St-Jacques Street.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 21st day of March, 1968.(Seal) Joseph Sobie, Secretary.24091-o 648-68 Quemat inc.Notice is hereby given that the company \"Quemat inc.\", incorporated in the Province of Quebec, by letters patent dated February 16, 1968.and having its head office in the city of Boucherville, district of Montreal, has established its principal place of business at number 111 de Lauzon Street, Boucherville, district of Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall l>e considered by the company as being its principal place of business and head office.Dated at Montreal, this 27th day of March, 1968.Jean-Claude Leroux, President.24092-o 751-68 Rycade inc.Notice is hereby given tliat \"Rycade inc.\", incorporated in the Province of Quebec by letters patent granted under the provisions of the Companies Act, bearing date the 30th day of January, 1968, and having its head office in the city and district of Montreal, Province of Quebec, has established its office at number 612 St.James St.West, Montreal, Que., c/o Mes.Geoffrion & Prud'homme, attention : Me Raymond G.Décary, Q.c.From and after the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Signed at Montreal, this fifth day of the month of February, 1968.Raymond Jean Décary, Secretary.24093 415-68 Peinture & Entretien Mercury Itée Mercury Maintenance & Painting Ltd.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Peinture & Entretien Mercury Itée \u2014 Mercury Maintenance & Painting Ltd.», constituée cn corporation par lettres patentes le 29 janvier 1968 a établi son bureau et siège social à 150 Haute Rivière, Châteauguay, district de Bcauharnois, Province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Montréal, le 30 janvier 1968.Le président, François Boisclair.24103-o 134-68 Peinture & Entretien Mercury ltéc Mercury Maintenance & Painting Ltd.Notice is hereby given that \"Peinture & Entretien Mercury liée \u2014 Mercury Maintenance & Painting Ltd.\", company incorporated by letters patent bearing the date of January 29, 1968, has established its office at 150 Haute Riviere, ChAteauguay, district of Beauharnois, Province of Quebec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Montreal, January 30th, 1968.François Boisclair, President.24103-o 134-68 2200 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, G avril 19G8, 100' année, n' U Salon Jade inc.Avis est présentement donné que la compagnie « Salon Jade inc.», constituée cn corporation par lettres patentes émises cn vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, en date du 22 août 1966, et ayant son bureau principal cn la cité dc Québec, a établi son bureau au no 1148 rue St-Jcan, cité de Québec.À compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Québec, ce huitième jour de novembre mil neuf cent soixante-sept 24094-o Jean-Paul Jolicoeub.Salon Jade inc.Notice is hereby given that the company \"Salon Jade inc.\", incorporated by letters patent bearing date the 22nd of August 1966, and having its head office in the city of Quebec, county of Quebec, has established its office in the said city, at number 1148 St John street.From and after the date of the present notice, the said office sludl be considered by the company as being its head office.Given at Quebec, this eighth day of November nineteen sixty-seven.24094-o Jean-Paul Jolicoeur.Domaine St.Augustin inc.Avis est donné que la compagnie < Domaine St.Augustin inc.», constituée en corporation par lettres patentes cn date du 18 mars 1968 a établi son bureau ù Stc Thérèse cn Haut, à 634 Mille Iles Ouest.A compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré comme étant le bureau principal dc la compagnie.Daté à Ste Thérèse en Haut, ce 18 mars 1968.Le secrétaire-trésorier.Normand Grimard.24100-o 1183-68 Domaine St.Augustin inc.Notice is hereby given tliat \"Domaine St.Augustin inc.\", incorporated by letters patent under date of March 18th, 1968, has established its head office at Ste Thérèse en Haut, at 631 Mille Iles Ouest.As and from this date, the said office is considered by the company as being its princial office.Dated at Stc Thérèse en Haut, this March 18, 1968.Normand Grimard, Secretary-Treasurer.24100-o 1183-68 La Fonderie Paccnrd Québec ltéc Avis est par les présentes donné que « La Fonderie Paccard Québec ltéc», incorporée en vertu dc la première partie dc lu Loi des compagnies par lettres patentes datées du 13 février 1967 a changé l'endroit dc son siège social du 10 rue dc Staël, Ville de Laval, au 50 rue de Staël, Ville de Laval.Montréal, le 27 mars 1968.IjC secrétaire, Pierre L.Lapointe.24101k) 608-67 La Fonderie Paccard Québec Itée Notice is hereby given that \"La Fonderie Paccard Québec ltéc\" incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patent dated February 13, 1967, has changed the place of its head office, from 10 de Staël Street, Town of Laval, to 50 de Staël Street, Town of Laval.Montreal, March 27, 1968.PiEitnE L.Lapointe, Secretary.24101 608-67 Industrial Protective Services Inc.Avis est donné que la compagnie < Industrial Protective Services Inc.», a été constituée en corporation cn vertu de la première partie de la Loi ries compagnies, par lettres patentes en «lato du 27c jour de février 1968, et que son siège social est situé ù 4520, avenue Old Orchard, Montréal, province de Québec.Daté à Montréal, ce 26c jour de mars 1968.Le secrétaire, A.Anthony Goodson.24102 922-68 Lou Petroleum Inc.Avis est donné que la compagnie « Lou Petroleum Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 20 mars 1968 a établi son bureau à Noranda, à 18 rue Richelieu.A compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré comme étant le bureau principal dc la compagnie.Daté à Rouyn, ce 20 mars 1968.Le secrétaire-trésorier, Robert Symington.24104-o 879-68 Industrial Protective Sendees Inc.Notice is given that \"Industrial Protective Services Inc.\" was incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patent dated the 27th day of February, 1968 and that its head office is situated at 4520 Old Orchard Ave.Montreal, Province of Quebec.Dated at Montreal, this 26th day of March.1968.A.Anthony Goodson, Secretary, 24102-o 922-6S Lou Petroleum Inc.Notice is hereby given that \"Lou Petroleum Inc.\", incorporated by letters patent under date of March 20th.1968, has established its head office in Noranda, at 18 Richelieu Street.As and from this date, the said office is considered by the Company as being its principal office.Dated at Rouyn, this March 20, 1968.Robert Symington, Secretary-Treasurer.24104-o 879-CS QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 19G8, Vol.100, No.1A 2201 Demandes à la Legislature Country Club of Montreal Avis est donné par les présentes que « Country Club of Montreal », s'adressera à fa Législature de la province de Québec à sa présente session afin d'obtenir une loi pourvoyant entre autres: a) qu'il sera gouverné par telle loi ainsi que par les dispositions de la Partie II de la Loi des compagnies de Québec; b) fixant le nombre d'actions du capital de la corporation; c) prévoyant que les actionnaires membres actifs ne pourront détenir qu'une action chacun du capital de la corporation; d) imposant des restrictions sur les transferts d'actions; e) prévoyant que nul autre qu'un actionnaire membre actif ne devra cn principe détenir d'actions dc la corporation; /) prévoyant que dans le cas d'une démission, expulsion ou décès d'un actionnaire membre actif, son action du capital actions doit être vendu ou transféré dans une période dc temps limite ù la suite dc laquelle le certificat d'action peut être annulé et l'action rachetée suivant des dispositions prévues aux règlements dc la Corporation; g) prévoyant que des actions de la corporation ainsi rachetées peuvent être ré émises; h) prévoyant que lors dc l'entrée en vigueur de la loi demandée, chaque détenteur d'action aura droit de recevoir pour chaque action alors détenue par lui une nouvelle action entièrement acquittée du capital de la corporation sujet au fait que seul les actionnaires membres actifs peuvent consefver telles actions et même alors sur la base de une action pour chaque actionnaire membre actif; i) prévoyant que lors dc l'annulation d'un rertificat d'action, le montant payable à la suite d'une telle annulation doit en certains cas être déposé avec une compagnie dc fiducie; j) autorisant la corporation à établir par règlement des honoraires d'admission, des frais de transfert, les cotisations annuelles payables par ses membres de même que leurs obligations cl privilèges et les conditions pour l'admission, la suspension ou l'expulsion des membres actionnaires actifs ou tous autres membres; k) telles autres fins qui sont énumérées dans la loi.Montréal, le 8 mars 1968.Les procureurs de la pétitionnaire, Bumbray, Carroll, Cardinal, 23816-11-4-0 Lajeunesse & Dansereau.La Cité de Salaberry-de-VaUeyficld Avis public est par les présentes donné que ' La Cité de Salaberry-de-Vallcyficld », s'adres-50ra ù la Législature de la Province de Québec, ù sa présente session, pour demander l'adoption d'une loi spéciale amendant sa charte pour les fins suivantes: 1° Établissement d'une commission appelée * Commission du Port dc Vallcyficld » et définition de ses droits et obligations; 2° Et pour autres fins.Salabcrry-dc-Volleyfield, ce 11 mars 1968.Le procureur, 238004 l-4-o Georges A.Melocue, c.r.Applications to Legislature Country Club of Montreal Notice is hereby given that \"Country Club of \"Montreal\", will make application to the Legislature of the Province of Quebec at its present session for the passing of an Act providing amongst other things: (a) that it shall be governed by such Act as well as by the provisions of Part II of the Quebec Companies' Act; (6) fixing the number of shares of the capital stock of the Corporation; (c) limiting the active shareholder members of the Corporation to the holding of one share only of the stock of the Corporation; (érant à l'étranger » a le sens (pic lui donne l'article 71 dc la Loi fédérale de l'ini|x\">t sur le revenu: c) compagnie non résidente » signifie toute compagnie non visée aux paragraphes a) et b) du présent article.2.Lorsque, dans une année financière, une compagnie a reçu un dividende d'une cora|>agnic qui a) était une compagnie canadienne durant l'année et n'était pas.aux termes d'une disposition statutaire, exempte de l'impôt sur le revenu pour l'année cn vertu de lu partie I de la Loi fédérale de l'i 1111 h'> t sur le revenu de la Loi de l'impôt sur les corporations, ou b) était une compagnie non résidente ou une compagnie opérant ù l'étranger dont plus dc 25 p.100 du cupital-actions émis (ayant en toutes circonstances plein droit dc vote) appartenaient ¦ i la compagnie bénéficiaire.un montant égal au dividende peut être déduit dans le calcul des profits dc cette compagnie pour l'année.3.Lorsque, dans sa déclaration dc revenu pour une année financière, une compagnie a, en vertu du présent règlement, déduit un montant à l'égard d'un dividende, aucune perte née d'opérations relatives à l'action concernant laquelle le dividende a été reçu n'est admise à réduire le revenu de la compagnie pour cette année financière ou pour une année financière subséquente, A moins que la compagnie n'établisse a) qu'elle était propriétaire de l'action trois cent soixante-cinq jours ou plus avant que la l>ertc ait été subie, et b) qu'elle n'était pas.au moment où le dividende a été reçu, propriétaire dc plus dc 5 p.100 de quelque catégorie du capital-actions émis de la compagnie de laquelle le dividende a été reçu.4.L'article 2 du présent règlement ne s'appli-ue pas aux compagnies de gestion qui ne font ans la province d'autres affaires que dc détenir des actions, obligations ou autres valeurs mobilières.5.Le présent règlement s'applique A l'année financière de toute compagnie qui se termine en 1967 et à ses années financières subséquentes.24136o and those received from another company and allowed for that purpose.Wherefore, It is ordered upon the recommendation of the Minister of Revenue: That the appended regulation entitled: \"Regulation concerning the deduction of dividends in computing profits and the Corporation Tax Act\" be adopted.Certified true copy.Jacques Prêmont, Clerk of the Executive Council.Regulation concerning the deduction of dividends in computing profits and the Corporation Tax Act (RSQ 1964, c.67 and amendments thereto).1.In this regulation, (a) \"Canadian company\" includes a company as defined in subsection 5 of section 2 of the Corporation Tax Act and doing business in Canada ond any other company taxable under subsection 1 of section 2 of the Federal Income Tax Act; (6) \"foreign business corporation\" has the meaning conferred to it in section 71 of the Federal Income Tax Act; (c) \"non-resident company\" means all companies not referred to in subsection (a) and (b) of this section.2.Where, in a fiscal year, a company bos received a dividend from a company which (a) was a Canadian company during the year and was not, by virtue of a statutory provision, exempt from income tax for the year under Part I of the Federal Income Tax Act or the Corporation Tax Act, or (b) was a non-resident company or a foreign business corporation, more than 25 per cent of the outstanding share capital of which (having full voting rights under all circumstances) belonged to the receiving company, an amount equal to the dividend may be deducted in computing the profits of that company for the year.3.Where in its return of income for a fiscal year, a company has, under the terms of this regulation, deducted an amount with respect to a dividend, no loss resulting from transactions with reference to the share in respect of which the dividend was received shall be allowed to reduce the income of the company for that fiscal year or for a subsequent fiscal year, unless it be established by the company (a) that it owned the stock three hundred and sixty-five days or longer before the loss was sustained, and (6) that it did not at the time the dividend was received, own more than 5 per cent of any class of the issued share capital of the company from which the dividend was received.4.Section 2 of this regulation does not apply to holding companies which carry out in the pn>-vince no other business than the holding of stocks, bonds or other securities.5.The present regulation shall apply to the financial year of every company terminating in 1967 and to its subsequent financial years.24136-0 GAZETTE OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100.No.li 2211 Association coopérative Association Cooperative Association coopérative de téléphone de Valcourt (Lot des associations coopératives) Avis est donné que le secrétaire de la province a approuvé la demande du syndicat coopératif « Syndicat coopératif du téléphone de Valcourt *, de cesser d'être régi par la Loi des syndicats coopératifs dc Québec, et de devenir une association régie par la Lui des associations coopératives, sous le nom de « Association coopérative de téléphone de Valcourt ».Quebec, le 1er avril 1968.Le soussecrétaire adjoint de la province, 21137-0 Lucien Darveau.Association coopérative dc téléphone de Valcourt (Cooperative Associations Act) Notice is hereby given that the Provincial Secretary has approved the request of the cooperative syndicate \"Syndicat coopératif du téléphone de Valcourt\", to cease to be governed by the Quebec Cooperative Syndicates Act, and to become an association governed by the Cooperative Associations Act, under the name of \"Association coopérative de téléphone de Valcourt\".Quebec, April 1, 1968.Lucien Darveau.Associate Assistant Secretary 24137 of the Province.Bill \u2014 Assemblée législative Bill \u2014 Legislative Assembly Chambre du Conseil législatif Québec.28 mars 1968.Aujourd'hui, à quatre heures de l'après-midi.i honorable lieutenant-gouverneur de la province -1 -t rendu A la chambre du Conseil législatif au Calais législatif.Les membres du Conseil législatif étant assemblés, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur d'y faire requérir la présence de l'Assemblée législative et, cette chambre s'y étant rendue, le grellier de la couronne en chancellerie a lu le titre du bill à être sanctionné comme suit: 20 I«oi octroyant à Sa Majesté des deniers requis |M)ur les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1969, et pour d'autres fins du service public.A ce bill, la sanction royale a été donnée dans les termes suivants: « Au nom dc Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur remercie ses fidèles sujets, ngréo leur benevolence et sanctionne ce bill.» 24080-o Legislative Council Chamber Quebec, 28th of March 1968.This day, at four o'clock in the afternoon, the Honourable the Lieutenant-Governor of the Province proceeded to the legislative Council Chamber in the legislative Building.The members of the legislative Council being assembled, the Honourable the Lieutenant-Governor was pleased to command the attendance of the Legislative Assembly, and that House being present the Clerk of the Crown in Chancery read the title of the bill to be sanctioned as follows: 20 An Act granting to Her Majesty moneys required for the expenses of the Government for the fiscal year ending on the 31st of March 1969, and for other purposes connected with the public service.To this bill the Royal assent was signified in the following words: \"In Her Majesty's name the Honourable the Lieutenant-Governor thanks her loyal subjects, accepts their benevolence and assents to this bill.\" 24080-o Chartes \u2014 Abandon de Charters \u2014 Surrender of Armitage South Shore Tire Co.Ltd.I'.n vertu des dispositions de la Loi des compagnies, telle que modifiée, « Armitage South SI >re Tire Co.Ltd.» donne avis par les présentes, quelle présentera une requête au secrétaire de la province de Québec pour qu'il accepte l'abandon de sa charte et cn ordonne son annulation et fi\\ UnC date ù compter dc laquelle elle sera dissoute.Montréal, P.Q., le 25 mars 1968.Le secrétaire, 240864 E.G.Shields.l'rencz incorporé vince de H charte.24057-o Bastion incorporé avis que la compagnie < Bastien », demandera au secrétaire de la proQuébec la permission d'abandonner Le procureur de la compagnie, Lomer Gervais, notaire.Armitage South Shore Tire Co.Ltd.Under the provisions of the Companies Act.as amended, \"Armitage South Shore Tire Co.Ltd.\", hereby give notice that it will make application to the Provincial Secretary of Quebec for acceptance of the surrender of its charter and to direct its cancellation and fix a date upon and from which it shall be dissolved.Montreal, P.Q., March 25.1968.E.G.Shields, 24056-o Secretary.Bastien incorporé Take notice that \"Bastien incorporé\", will apply to the Quebec Provincial Secretary for leave to surrender its cliartcr.24057 Lomer Gervais.notaire.Attorney for the company. 2212 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100' année, n\" lk Smaliwood Markham Adveroiting Inc.Avis est donné qu|en vertu des dispositions dc la Loi des compagnies, « Smaliwood Markham Advertising Inc.», demandera au secrétaire dc la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte et l'annulation d'icelle à compter d'une date qu'il lui plaira de fixer.Daté à Montréal, ce 24 novembre 1967.24066 Joseph P.Smallwgod.Smaliwood Markham Advertising Inc.Under the provisions of the Companies Act, \"Smaliwood Markham Advertising Inc.\", hereby gives notice that it will make application to the Secretary of the Province of Quebec for a< \u2022 ceptancc of the surrender of its Charter and iu cancellation on an from a date to be fixed by him.Dated at Montreal, this November 24th, 1967.24066-o Joseph P.Smallwood.Cité Automobile limitée Prenez avis que « Cité Automobile limitée », s'adressera au secrétaire de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa cliarte.Chicoutimi, le 25 mars 1968.Les avocats et soliciteurs Chouinard.Prévost 24058-o & Casokain.City Automobile Ltd.Take notice that \"City Automobile Ltd.\", will apply to the Provincial Secretary of leave to surrender its charter.Chicoutimi, March 25, 1968.Chouinard, Prévost & Casobain, 24058-o Barristers and Solicitors.Cornell Realties Inc.Avis est donné que « Cornell Realties Inc.», une corporation dûment constituée en vertu de la Loi des compagnies s'adressera au secrétaire dc la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 12 mars 1968.Le procureur dc la requérante, 24059 Hi ask a Gyulai.Lachine l.adie- Wear Inc.Avis est par les présentes donnée que « Lachinc Ladies Wear Inc.», demandera au secrétaire de la province de Québec la permission d'abandonner sa cliarte.selon la Loi des compagnies.Montréal, le 12 mars 1968.Le Procureur, 24060-o Philip S.Garonce.Ray-Fort Inc.Avis est donné par les présentes, que la compagnie « Ray-Fort Inc.», constituée en corporation par lettres patentes cn date du 11 mai 1966, demandera au secrétaire dc la province la permission d'abandonner sa charte.Rimouski, ce 18 mars 1968.Le procureur de la compagnie, 24061-o Joseph Bérubé.notaire.Ritz Supplies Inc.La compagnie « Ritz Supplies Inc.», incorporée suivant la première partie dc la Loi des compagnies, le 10 septembre 1958, par lettres patentes enregistrées le 23 septembre 1958, donne avis qu'elle demandera au secrétaire de la province de Québec l'autorisation d'abandonner sa charte et demandera qu'une date soit fixée pour la cessation des affaires de la compagnie.Montréal, le 23 février 1968.Les procureurs de la requérante, 24062-n Jasmin & Marcoux.Salon Épilatoire Louiscttc inc.Prenez avis que la compagnie « Salon Épilatoire Louisctte inc.», demandera au secrétaire de la province la permission d'abandonner sa charte.Le président de la compagnie, 24063-0 Gérard Desbiens.Cornell Realties Inc.Notice is hereby given tliat \"Cornell Realties Inc.\", corporation duly incorporated under the Quebec Companies act, will apply to the Secretary of the Province of Quebec for the surrender of its charter.Montreal, March 12.1968.Blank a Cyilai.24059-0 Attorney for Petitioner.Lachinc Ladies Wear Inc.Notice is hereby given that \"Lachine Ladici Wear Inc.\", will make application to the Secretary of the Province of Quebec for leave to surrender its charter, in accordance with the Companies Act.Montreal, March 12.1968.Philip S.Garonce, 24060-o Attorney.Ray-Fort Inc.Notice is hereby given that \"Ray-Fort Inc.\", incorporated by letters patent dated May 11, 1966, will apply to the Provincial Secretary for leave to surrender its charter.Rimouski, March 18, 1968.Joseph Bérubé, notaire, 24061 Attorney for the Company.Ritz Supplies Inc.The company \"Ritz Supplies Inc.\", incorporated under the Part I of the Companies Act, on September 10, 1958, by letters patent registered at Quebec on September 23, 1958, gives notice that it will apply to the Secretary of the Province of Quebec to ask to be authorized to surrender its charter, that the said charter he annulled and that a date he fixed at which the company shall be dissolved.Montreal, February 23, 1968.Jasmin & Marcoux, 24062-o Attorneys for the Petitioners.Salon Épilatoire Louisette inc.Take notice that \"Salon Épilatoire Louisctte inc.\", will apply to the Provincial Secretary for leave to surrender its charter.Gérard Desbiens, 24063-o President of the Company. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.1A 2213 Samson & Fils inc.Avis est donné que < Samson & Fils inc.», corporation légalement constituée suivant la première partie de la Loi des compagnies et ayant sa principale place d'affaires à Levis, P.Q., s'adressera au secrétaire de la province pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Québec, le 26 mars 1968.Lu procureurs de la compagnie, Turgeon, Amyot, Choquette 24064-o et Lesaoe.Sealine Development Ltd.Avis est par les présentes donné que < Sealine Development Ltd.», une corporation constituées sous la Loi des compagnies et ayant son bureau principal en la ville de Montréal, s'adressera au secrétaire de la province de Québec, pour obtenir In permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, P.Q., ce 21e jour de mars 1968.Le secrétaire-trésorier, 24065-0 Kathleen Doran.Crescent Management Corporation Avis est par les présentes donné que « Crescent Management Corporation », corporation dament incorporée suivant la Loi des compagnies et ayant son siège social cn les cité et district de Montréal, fera application au secrétaire provincial de la province de Québec aux 6ns d'abandon de sa charte suivant les dispositions de la Loi dos compagnies.Fait et passé à Montréal, ce dix-septième (17e) jour dc janvier mil neuf cent soixante-huit ( 1968).Le tice-président, Jacques Bélanger.2407 l-o 13049-62 Elic Tabah Trading Ltd.Prenez avis que la compagnie « Elic Tabah Trading Ltd.».demandera au secrétaire de la province la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 24082-o Albert H.Maloi-p, c.r.Daignault & Fils inc.Prenez avis que < Daignault & Fils inc.», demandera au secrétaire de la province la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 27 mars 1968.Les procureurs de la compagnie, Trudel, Beaudry, Gamache & 24139-0 Nadeau.Gloria Gloves (Canada) Ltd.Avis est donné par les présentes que « Gloria 'iloves (Canada) Ltd.», une corporation incorporées suivant la Loi des Compagnies et ayant son bureau chef dans la cité de Montréal, s'adressera au secrétaire provincial de la province de (Juchée pour obtenir la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 1er jour d'avril, 1968.Le secrétaire, 24140-o Raphaël E.Elias.Samson & Fils inc.Notice is given that \"Samson & Fils inc.\", incorporated under the Part I of the Companies Act and having its principal place of business at Levis, P.Q., will apply to the Provincial Secretary for leave to surrender its charter.Quebec, March 26.1968.Turgeon, Amyot, Choquette and Les age, 24064-0 Attorneys for the Company.Sealine Development Ltd.Notice is hereby given that \"Sealine Development Ltd.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Provincial Secretary of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, P.Q., this 21st day of March, 1968.Kathleen Doran, 24065-0 Secretary-Treasurer.Crescent Management Corporation Notice is hereby given that \"Crescent Management Corporation\", a corporation duly incorporated pursuant to the Companies Act, and having its head office in the city and district of Montreal, will apply to the Provincial Secretary of the province of Quebec for leave to surrender its charter, pursuant to the provisions of the Companies Act.Made and passed in Montreal, this seventeenth (17th) day of January, one thousand nine hundred and sixty-eight (1968).Jacques Bélanger.Vice-president, 24071 13049-62 Elie Tabah Trading Ltd.Notice is hereby given that \"Elie Tabah Trading Ltd.\", will apply to the Provincial Secretary for leave to surrender its charter.Albert H.Maloup, q.c, 24082 Attorney for the Company.Daignault & Fils inc.Notice is hereby given that \"Daignault & Fils inc.\", will apply to the Provincial Secretary of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.Montreal, March the 27th, 1968.Trudel, Beaudry, Gamache & Nadeau, 24139 Attorneys of the company.Gloria Gloves (Canada) Ltd.Notice is hereby given that \"Gloria Gloves (Canada) Ltd.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Provincial Secretary of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 1st day of April, 1968.Raphael E.Elias, 24140-o Secretary. 2214 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100' année, n\" 14 Musique & Sports Itée Avis est donne conformément a la Loi des compagnies, que la compagnie « Musique & Sports Itée», demandera au secrétaire de la province dc Québec, la permission d'abandonner sa charte.Daté à Chicoutimi, ce 1er jour d'avril 1968.Les procureurs de la compagnie, 24141-0 Dukouh, Tremblay & Lakouciie.Musique & Sports Itée Notice is hereby given that the company \"Musique & Sports Itée\", will apply to the Secretary of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Chicoutimi, this 1st day of April 196S.Dufour, Tremblay & La hou cm , 24141-0 Attorneys for tlie company.Divers Miscellaneous Compagnies Companies Compagnie Générale de Placement, limitée General Investment Company, Limited Avis est donné que la « Compagnie Générale de Placement, limitée \u2014 General Investment Company, Limited » a fixé le nombre dc ses administrateurs à 3.Le secrétaire.Lorraine Côte.24067-o 13444-57 Compagnie Générale de Placement, limitée General Investment Company, Limited Notice is hereby given that \"Compagnie Générale de Placement, limitée \u2014 General Investment Company, Limited\", has fixed the number of its directors to 3.Lorkaine Côte, Secretary.24067 13444-57 Hermann Fortier incorporée Avis est donné que la compagnie « Hermann Fortier incorporée » a changé le nombre dc ses administrateurs dc 4 à 3.Le secrétaire, Juliette R.Fortier.24068-o 446-33 Hermann Fortier incorporée Notice is hereby given that \"Hermann Fortier incorporée\", has changed the number of its directors from 4 to 3.Juliette R.Fortier, Secretary.24068 446-33 Nesbill, Thomson and Company, Limited Ni-I>iii.Thomson et Compagnie, limitée Avis est donné que « Nesbitt, Thomson and Company, Limited \u2014 Nesbitt, Thomson et Compagnie, limitée» a changé le nombre dc ses administrateurs, de 25 ù 26.L'ass istant -sec rétaire, G.R.Browne.24060 5149-52 Nesbitt, Thomson and Company, Limited Nesbitt, Thomson et Compagnie, limitée Notice is given that \"Nesbitt, Thomson and Company, Limited \u2014 Nesbitt, Thomson et Compagnie, limitée\" has changed the number of its directors from 25 to 26.G.R.Browne, Assistant-Secretary.24069-o 5149-52 La Jeune Chambre d'IIébcrtvillc-Slation Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 14 mars 1968, approuvé le règlement numéro 1 des règlements généraux de la corporation \u2022 La Jeune Chambre d'Hébcrtvillc-Station », et ce, cn vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24085-o 2218-67 Loranger & Frères ltéc Le 26 mars 1968, le règlement no 29 a été adopté par la compagnie pour la distribution à ses actionnaires de tout l'actif de la compagnie.Le secrétaire, 24086-o (Signé) Roger Loranger.La Jeune Chambre d'Hébcrtvillc-Station Notice is hereby given that the Provincial Secretary, on March 14, 1968, approved by-law number 1 of the general by-laws of \"La Jeune Chambre d'Hébcrtvillc-Station\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24085 2218-67 Loranger & Frères ltéc On March 26,1968.by-law No.29 was adoptc.l by the company for the distribution of all company assets to its shareholders.(Signed) Roger Lorancer, 24086 Secretary.Société des Travailleurs des Mines, inc.Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 14 mars 1968, approuvé le règlement numéro 1 des règlements généraux de la « Société «les Travailleurs des Mines, inc.», et ce, en vertu dc l'article 225 de la Loi des compagnies.Société des Travailleurs des Mines, inc.Notice is hereby given that the Provincial Secretary, on March 14, 1968, approved by-law number 1 of the general by-laws of \"Société des Travailleurs des Mines, inc.\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24087 33-6* Le soussecrétaire de la province, Raymond Douville.24087-o 33-68 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.Ik 2215 Les Amie des Mouvements Scout et Guide de Charlemagne Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 22 mars 1968, approuvé les règlements numéros 1 et 2 de la corporation « Les Amis des Mouvements Scout et Guide de Charlemagne », et ce, en vertu de l'article 225 dc la Loi des compagnies.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.21099-o 1054-67 Conseil Dante, No 3179, des Chevaliers de Colomb Avis est donné que le secrétaire de la province a.le 21 mars 1968, approuvé les règlements généraux de la corporation « Conseil Dante, NO 3479, des Chevaliers de Colomb », et ce, cn vertu dc l'article 9 de la Loi concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec et dc l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24109-o 2037-67 Association Provinciale des Constructeurs d'Habitations du Québec inc.Quebec Provincial Home Builders Association Inc.Avis est donné que le secrétaire dc In province a.le 25 mars 1968, approuvé le règlement numéro 1 (règlements généraux: articles 1 ù 54 inclusivement, dont l'article 21 augmente les administrateurs dc 3 à 15) de I'« Association Provinciale des Constructeurs d'Habitations du Québec inc.\u2014 Quebec Provincial Home Buil !ers Association Inc.», et ce, cn vertu dc l'article 225 dc la Loi des compagnies.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24121-0 14918-62 Boutiques Les Impeccables inc.Avis est donné que la compagnie « Boutiques I.cs Impeccubles inc.», a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Ia secrétaire, Yves Rinfret.24125-o 747-68 Les Amis des Mouvements Scout et Guide de Charlemagne Notice is hereby given that the Provincial Secretary has, on March 22, 1968, approved by-law numbers 1 and 2 of \"Les Amis des Mouvements Scout et Guide de Charlemagne\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24099 1054-67 Council Dante, No.3479, of the Knights of Columbus Notice is hereby given that the Provincial Secretary, on March 21, 1968, approved the general by-laws of \"Council Dante, No.3479, of the Knights of Columbus\", and such, pursuant to section 9 of the Act respecting the Knights of Columbus of the Province of Quebec and to section 225 of the Companies Act.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24109 2037-54 Association Provinciale des Constructeurs d'Habitation du Québec inc.Quebec Provincial Home Builders Association Inc.Notice is hereby given that the Provincial Secretary has, on March 25, 1968, approved the by-law number 1 (general by-laws: sections 1 to 54 inclusively, whose section 21 increases the directors from 3 to 15) of l'\"Association Provinciale des Constructeurs d'Habitations du Québec inc.\u2014 Quebec Provincial Home Builîers Association Inc.\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24124 14918-62 Boutiques Les Impeccables inc.Notice is hereby given that \"Boutiques Les Impeccables inc.\", has changed the number of its directors, from 3 to 4.Yves Rinfret, Secretari/.24125 747-68 Sunnybrook Swimming Pool Association Sunnybrook Swimming Pool Association Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 26 mars 1968, approuvé les règlements généraux de « Sunnybrook Swimming Pool Association », et ce, en vertu dc l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-secretaire de la province, Raymond Douville.24126-0 2141-67 Ligue Électrique de Québec (Erratum) Quebec Electrical League (Erratum) (Erratum) Dans l'avis concernant l'approbation du règlement numéro 2 (règlements généraux) de la ' Ligue Électrique de Québec \u2014 Quebec Elec-trical League », publié dans le numéro 12 de la Gazette officielle dc Québec, du 23 mars 1968, à la page 1876, au lieu de « article 225 », il faut lire «article 226».Le sous-secretaire de la province, 21053-o Raymond Douville.Notice is hereby given that the Provincial Secretary has, on March 26, 1968, approved the general by-laws of \"Sunnybrook Swimming Pool Association\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24126 2141-67 Ligue Électrique dc Québec Quebec Electrical League (Erratum) In the notice concerning approval of by-law number 2 (general by-laws) of the \"Ligue Électrique de Québec \u2014 Quebec Electrical League\", published in number 12 of the Quebec Official Gazette, on March 23, 1968, on page 1876, instead of \"section 225\", please read \"section 226\".Raymond Douville, 24053 Assistant Secretary of the Province. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, C avril 1998, 100' année, n° 14 Sunnyhrook Swimming Pool Association Sunnybrook Swimming Pool Association Avis est donne que « Sunnybrook Swimming Pool Association » a changé le nombre de ses administrateurs, de 3 ù 13.Le Secrétaire, Michael FoSTATT.24120 2141-G7 Notice is given that \"Sunnybrook Swimming Pool Association\" has changed the number «I its directors from 3 to 13.Michael Fostaty, Secrclan/.24126-0 2141-1.7 Association des Entreprencura en Travaux Municipaux des l.aiircntides inc.Avis est donné que Ic secretaire dc la province a, le 27 mars 196S, approuvé les règlements généraux de l'« Association des Entrepreneurs en Travaux Municipaux des Laurcntidcs inc.», et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le soils-secretaire de la province, R a y.mon d L)ot : vi i.i.e.24142-0 4744-67 Association «les Kntrepreneurs en Travaux Municipaux des Laurcntidcs inc.Notice is hereby given that the Provincial Secretary has, on .March 27, 1068, approved the general by-laws of \"Association des Entrcpn neun en Travaux Municipaux des Laurent ni .inc.\", and such, pursuant to section 225 of the ( 'ompanics Act.Raymond Docvillb, Assistant Secretary of the Province.24142 4744-67 association «les Entrepreneurs en Travaux Municipaux des Laurcntidcs inc.Avis est donné que l'« Association des Entrepreneurs en Travaux Municipaux des Laurcntidcs inc., a change le nombre de ses administrateurs dc 3 à 7.Le secrétaire, Georges Wi iitele.24142-0 4744-g7 (.lob du Petit Lac Brampton Avis csl donné «pie le secrétaire de la province a, le 19 février 1968.approuvé les règlements généraux de la corporation « Club du Petit Lac Bromplnn \u2022>, et ce.en vertu de l'article 8 de la Loi de* clubs île récréation et «le l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-secr/taire dc la province.Raymond Douville.24083-o 52-67 Quebec Natural Gas Corporation ('orporation «le G ai Naturel du Quebec Avis est donné «pie la « Quebec N'atural Cas Corporation\u2014Corporation de (>az Naturel du Québec a changé le nombre dc ses administrateurs de 12 à 10.Le secrétaire, Camille Antaki.24081 11674-55 Association «l«'s Entrepreneurs en Travaux .Municipaux des Laurcntidcs Inc.Notice is hereby given that \"Association des Entrepreneurs en Travaux Municipaux des Laurcntidcs inc.\", has changed the number «if its directors from 3 to 7.Georges Wubtele, Secretary, 24142 4741-67 Club «lu Petit Lac Brompton Notice is hereby given that the Provincial Secretary has.on February 19.196S, approved the general by-laws of \"Club du Petit Lac Brompton\".and such, pursuant to section S of the Amusement Clubs Act and section 225 of the Companies Act Raymond Dorvn.i.i:.Assistant Secretari) of the Province.24083 52-67 Quebec Natural Gas ('orporation Corporation de Gaz Naturel du Québer Notice is given that \"Quebec Natural Gas Corporation\u2014Corporation de Gas Naturel «lu Quebec\" has changed the number of its director-from 12 to 10.Camille Antaki.Secretary.240S4-o 11074-55 Caisses d'épargne et de crédit Caisse d'économie «les employés de Tioxidc du Canuda I Loi des caisses d'épargne et dc crédit) Avis est donné «pie le secrétaire de la province a approuvé la formation de la caisse d'épargne et de crédit « Caisse d'économie «les employés ¦ le Tioxidc du Canadu I \u2022 groupe dans lequel la caisse recrutera ses membres sera les employés dc Tioxidc du ( 'anada Limitée, à Sorcl.Le siège social de cette cuisse d'épargne et «le Crédit est situé à Sorel, Québec, dans le district électoral de Itichclicu.Québec, le 28 mars 1908.Le soussecrétaire adjoint de la province, 240S1-o Licien Daiive.u.Savings and Credit Unions Caisse d'économie «les employés de Tioxidc du Canada (Savings and ('redit Unions Act\\ Notice is hereby given that the Provincial Secretary lias approved the formation of the savings uud credit union \"Cuisse d'économie de» employés «le 'Tioxidc du Canada\".'The group from which the union will recruit its members will be the employees of 'Tioxidc du Canada Limitée, ut Sorel.'The head oflice of this savings and credit union is situated at Sorcl.Quebec, in the electoral disl rict of Richelieu.Quebec, March 2S.1968.Lucien Darveau, Associate Assistant Secretari/ 24081 of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No./.', 2217 La Caisse populaire de St-Eugène de Granby (Loi des caisses J'épargne el de crédit) Avis est ilonné que le secrétaire Saint-Gérard, county of Wolfe\", has been incor poratcd by a Municipal Council By-law on tie 6th of November 1899; Whereas the Municipal Council has adopted al a general meeting held on the 5th of,hue 1067, a By-law to the clfecl of repealing tie By-law having incorporated the said company to which present members of the company hav< given their approbation; Whereas the secretary-treasurer of the said Municipality has filed, on the 1st of December 1967, with the Insurance Branch, a sworn deehi ration to the effect thai the company had cancel led all its policies, discharged all its debts and distributed its surplus; Therefore, notice is hereby given that the li cense and registration of \"La Compagnie d'Ai surance Mutuelle contra le Feu dc la Municipaliti du Village de Saint-Gérard, county of Wolfe\" are cancelled as from the 1st of April 1068.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 1st of April 1968.For the Minister < f Finance fifths Province, Roger \\ Cauaraire, 2-1108-1 l-2-o Superintendent of Insurance, Ministère de l'Education Department of Education Dundee Demande est faite «l'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire «le Dundee, dans le comté de Huntingdon, à la municipalité scolaire «le Huntingdon, dans le comté dc Huntingdon.20 murs 1968.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.23970-13-2 618-65 Fini hurst and East Greenfield (l'rot.) Demande est faite d'annexer le territoire actuel dc la municipalité scolaire de Pinehursl et Fast Greenfield (l'rot.), dans le comté «le Chanibly, ù la municipalité scolaire de Saint-Hubert (l'rot.) dans le comté de Taillon.Le 1er avril 1068.Le ministre dc l'Education, 21107-11-2 Jean-Guy Cardinal.Stanstcad County (Prot.) Erratum Dans l'avis publié dans le volume 100.numéro 12.cn date du 23 mars l'.ltiS.sur la page 1S85.concernant la municipalité scolaire protestante du coin lé de Compton.lu 3e ligne du dernier paragraphe devrait se lire comme suit: « North Hal ley el 11ut 1 -y Villuge dans le comté de Stanstcad au lieu de » North Ilalley Milage dans le com lé de Stanstcad .27 mars 1968.Le ministre de l'Education, 24070 Jean-Guy Car dix al.Dundee Application is made to annex the present territory of the school municipality »f Dundee, in the county of Huntingdon, to the school municipality of Huntingdon, in the county of Huntingdon.March 20, 1968.Iean-Giv Cardinal, Minister of Education, 2397G-13-2-0 ti 1 SO\", Pinehursl and Fast Greenfield (Prot.) Application is made to annex the present terri tory of the school municipality of Pinehiirst and Fast ( Greenfield (Prot ).in the county of ( 'liamhh to the school municipality of St.Hubert (Prot.) in the count v of Taillon.April I.1908, Jean-Guy Cardinal, 21107-l-l-2-o Minister of Education.Stanstcad County (Prot.) Erratum In the notice published in Volume 100, Numbei 12.dated March 23.190S on page 1885 concern ing the Protestant school municipality ol Compton County, we should read in the 3rd.line of tin last paragraph \"North Ilatley and Hut Icy Village in the county of Stan stead\" instead oi \"North Ilatley Village in the County of Stan stead\".March 27, 190S.Jean-Guy Car din al, 24076-o Minister of Education. QUEBEC OFFICIAI.OAZETTE, April c.ions.Vol.wo.No.1J, 2219 Kégic des Marchés Quebec Agricultural Agricoles du Québec Marketing Board Modifications au plan conjoint des producteurs dc bois de pulpe du Sagucnay Prenez avis que l'o'lice des producteur! dc bois Je pnlpe du Sagucnay, corps politique légalement constitué sous l'empire de la Loi des marchés agricoles du Québec et ayant son siège social à Chicoutimi chargé de l'application du plan ciiii-i.iiul des producteurs de bois de pulpe du Saguc-lay, a déposé à la Régie des marchés agricoles une requête pour soumettre au référendum des producteurs intéressés, les amendements suivants nu plan conjoint précité: m Abroger la désignation de « Plan conjoint îles producteurs de bois de pulpe du Sagucnay * 11 la remplacer par « Plan conjoint des producteurs de bois du Sagucnay ».h' Abroger la désignation de \" Olliec des producteurs de bois de pulpe du Sagucnay et la remplacer par « Office des producteurs de bois du Sagucnay .cl Substituer aux mots: « Mois dc Pulpe », partout OÙ ils apparaissent dans le plan conjoint, le mot: * Bois .il\\ Abroger les mots: huis producteurs-fournisseur dc bois de pulpe aux compagnies forestières ou autres acheteurs de la Province de Québec, faisant affaires duns lu ¦ gion du Sagucnay, comprenant les comtés dc ( hicoiilimi, Joiiqiiièrc-kénogami, Lue St-Jean cl Biilicrvul » apparaissant au troisième paragraphe du plan \u2022 -nijoint et les remplacer par les mots: tous producteurs dc bois de la région du Sagucnay, comprenant les Comtes de Chicoutimi, I Mil nie, Joiiqiiièrc-kénogami, Lac Sl-.lcau et lioberval .r) Abroger les deux paragraphes du préam-bul \u2022 de lu section du plan conjoint intitulé « Pouvoir» el attributions» et les remplacer par les dispositions suivantes: \u2022 Négocier avec tout acheteur et toute autre partie accréditée par la Régie des marchés agricoles, en vertu de l'article 27 de lu Loi des marchés agricoles ».GfnfroUment: La mise eu marché et la vente des bois feuillus ou résineux provenant du boisement de toute personne «pli le possède à titre ,1e propriétaire ou ,i qiiclqu'uutrc titre que ce soit, «pli peut en mettre le produit cn marché./) Amender le paragraphe « / \u2022 nyant trait au financement du plan conjoint en ajoutant les mots: ou son équivalent > après les mots: « 0.33 cents par corde «le bois mesurant 4x8*4».y) Abroger tous les mots «pli suivent le mot: \u2022 consommateur - au paragraphe « a » des amendements sanctionnés le 17 mars 1959.h) Ajouter au plan conjoint les dispositions suivantes: 1) Ksi un pro hicleur intéressé toute personne, propriétaire ou possesseur à quelque titre que ce soit, d'un boisement couvrant une superficie de 20 acres et plus, sis dans les comtés de ( 'hicou-timi, Duhuc, Joiiqiiière-Kéiiogami.Lac St-Jean et lioberval «pli peut en mettre le produit cn marche.2) Sauf dans les cas où la Loi des marchés agri-oles assujettis l'application d'un règlement à su publication dans la Gazette officielle de Québec, la publication des règlements ayant rapport aux Amend men ts to a joint plan of the Saguenaj Pulpwood Producers Notice is given that the Sagucnay Pulpwood Producers' Board, holy politic legally incorporated under the Quebec Agriciilliiienl Marketing Act and having its head office at Chicoutimi, entrusted with the application of the Siguenay pulpwood producers' joint plan, has applied to the Agricultural Marketing Board requesting that the following amendments to the hereinabove joint plan be submitted to the referendum of Ihe interested producers: (a) To repeal the designation \"The Siguenay Pulpwood Producers' Joint Plan\" and replace it with \"The Sagucnav Wood Producers Joint Plan\".(b) To repeal the designation \"The Sagucnay Pulpwood Producers' Board\" and replace itwilli \"The SagUenay Wood Producers' Board\".(r) To replace the word \"Pulpwood\" wherever it appears in the joint plan by the word \"Wood\".(d) To repeal the words: \"who must be producers-suppliers of pulpwood to the forestry Companies and other buyers of the Province of Quebec doing business in the Sagucnay region, which comprises the counties of Chicoutimi.Joiupiièrc-Kénogami, Lie St.Jean ami Robcrval.\" which appear in the third paragraph of the joint plan and replace them by: \"who must be wood producers of the Sagucnay region, which comprises the counties of Chicoutimi, Diibuc.Joiiqiiièic-Kénogami.Lac Saint-Jcan and Robcrval.\" (r) To repeal the two paragraphs of the preamble of the joint plan section called \"Powers and attributions\" ami replace then with the following resolutions: \"Negotiate with any buyer and with any other party duly accredited by the Agricultural Marketing Board, pursuant to section 27 of the Agricultural Marketing Act.\" Generally: The marketing and sale of hardwood ami softwood deriving from the wood lot of any person who owns il as proprietor or by any other right, wdio can market the product thereof.(/) Amend paragraph (1) concerning the financing of the joint plan by adding the words: \"or its equivalent\" following the words \"thirty-five cents (SO.35) per cord measuring 4 x 8 x 4\".(j;) Repeal all the words following the wor I \"Consumer\" in paragraph (n) of the amendments assented to March 17.1959.(//) Add to the joint plan the following resolutions: 1.Is an interested producer any person, proprietor or owner by any other right, of a wood-lot having a total area of 20 acres nml more, located in the counties of Chicoutimi, Dubuc, Jonqiiière-Kénogami, Lac Saint-Jean and Robcrval, wdio can market the product thereof.2.Save in the cases where the Agricultural Marketing Act subjects the application of a by-law to its publication in the Quebec Official Gazette, the publication of by-laws relating to the 2220 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 0 avril IOCS.100' année, n° I', modalités d'exécution du plan conjoint et à l'exercice des pouvoirs dc l'o'lice sera faite dans les langues française et anglaise pour parution duns le journal « La Terre de cliez-nous ».3) Au cas de divergence entre le texte français et le lexle anglais du présent plan conjoint, ou d'un règlement, le texte français prévaudra.4) L'Ollice pourra, au moyen d'une résolution cpii pourra cire approuvée par la Régie îles marches agricoles, modifier la contribution que les producteurs intéressés sont tenus de payer pour l'administraiiou du plan conjoint.Cette requête srra élu liée par les membres de la Régie îles marchés agricoles du Qu.bec le mercredi 10 avril prochain et, si elle est reçue, les amendements projetés seront soumis aux producteurs au moyen du référendum prévu ù l'article 25 dc la Loi des marchés agricoles du Québec.Montréal, ce 2S mas 190S.I,e président, Maurice H w.i.é.Le secrétaire intérimaire, 2100S-o Hocii Moaix.ways and means of execution of the joint plan and to the exercice of the board's piwcrs will be made in the French and English languages to appear in the newspaper \"La Terre de chez nous\".3.In the case of any difference between the Franeh text and the English text of the present joint plan, or of a by daw, the French text shall prevail.4.The Board can modify, by means of a resolution to be approved by the Agricultural .Marketing Board, the fees which the interested producers are bound to pay for the application of the joint plan.This request shall be studie 1 by the members of the Quebec Agricultural Marketing Board on We lues lay, April 10th next and, if approved, the planned amendments shall be submitted to the pro lucers by means of a referendum as state I in section 25 of the Quebec Agricultural Marketing Act.Montreal, March 28, 1008.Maurice Halls, President.Rocu Moms', 24098 Interim Secretari/.Syndicats professionnels Professional Syndicates Association drs Camionneurs Artisans du Comté de Chameau (Loi des syndicats professionnels) La constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom île « Association des Camionneurs Artisans du < îomlé de ( 'nouveau .a été autorisée par le secrétaire de la province le 15 mars 1908.Le siège social dudit syndicat professionnel est situé à 8325.boulevard IIcuri-Bourassa, Charlcsbourg.district judiciaire de Québec.Québec, le 19 mars 1908.Le sous-secretaire dc la prorince.Raymond Douville.24077-o 17-08 I ' Association des Employés dc Scott La Salle (Loi des syndicats professionnel) Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 22 mars I96S.autorisé le changement de nom de |'« Association of Employees of Scott Clothing Co.Ltd.\\ %, payable semi-annuellc-nt les lermaiet 1er novembre île chaque année Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant un taux d'intérêt différent lourra, en plus du taux d'intérêt initial, être eepté dans le cas des obligations émises à ourte échéance 10 ans ou 15 ans, pourvu que es montants ainsi émis, à ce taux différent, ¦'ient pour des échéances entières, cn tenant oinpte du tableau d'échéance apparaissant dans le présent avis.Résolution d'emprunt en date du 2 mai 1967 \u2014 \"\u2022725,000 \u2014 Construction de l'école secondaire le \\otrc-I)ame-du-Sourire.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera alculé à comper du 1er mai 1968.Capital and interests are payable ut ull branches in the Province of Quebec of the bunk whose name is mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and as 20-year fixed-term bonds, for an amount equal to $132,000 or less.However, if they are issued in part as 20-year fixed term for an amount higher than $132,000.the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on May 1, of each year for the annual amount required to amortize the issue pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Wednesday, April 24.1968.at 5:00 o'clock p.m.at the Town Hull.9 Montcalm Hlvd., Candiac, county of Xapicrville-Lupruiric.P.Q.'The council does not hind itself to accept the highest or any of the tenders.Candiac.(Countv of Napierville-Laprairie), March 28, 1908.Hélène Sentenne, Secretary-Treasurer.Town Hall, 9 Montcalm Blvd.Candiac, (Napierville-Laprairie), P.Q.Telephone: 659-5433, code 514.24079 The Verdun Catholic School Commission County of Montreal-Verdun Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for bonds\", will be received by the undersigned Paul Roy.secretary-treasurer.Administrative Office of the School Commission, 4480Champlain Boulevard.Verdun, county of Montreal-Verdun, until 7.30 o'clock, p.m., Tuesday, April 23, 1968, for the purchase of an issue of $725,000 of lxmds for the Verdun Catholic School Commission, county of Montreal-Verdun, P.Q., dated Mav 1, 1968, and redeemable serially from May 1.1969 to May 1, 1988.inclusively, with interest at a rate not less than 6^%.nor more than 7!£%.payable semiannually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, a different rate of interest could, in addition to the initial interest rate, be accepted us bonds issued as 10-year or 15-year short-term bonds, provided that the amounts thus issued, at this different rate, be for entire maturities, bearing in mind the maturity table appearing in the present notice.Loan resolution dated May 2, 1967 \u2014 $725,000 \u2014 Construction of Notre-Oame-du-Sourire Secondary School.For adjudication only, interest shall be calculated as from May 1, 1968. 222i i GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, G avril 1968, 100' année, n\" U Tublcau d'amortissement \u2014 8725,000 - 20 ans Année Capital 1er mai 1909 $18,000 1er mai 1070.10,000 1er mai 1971 20,000 1er mai 1972 22.000 1er mai 1973.23,000 1er mai 1974 .25,000 1er mai 1975.26,000 1er mai 1970.28,000 1er mai 1977.30,000 1er mai 1078 .32,000 1er mai 1979 .35,000 1er mai 1980 37,000 lcrmail981 .40.000 1er mai 1982 43.000 1er mai 1983 40,000 1er mai 1984 .49,000 1er mai 1985 52,000 1er mai 1986 .50.000 Icrmai 19N7.00.000 1er mai 1988 04,000 De plus, îles soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois ternies.L'adjudication sera fuite conformément à lu loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Verdun.Le eapilal et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ont.Lesdites obligations ne seront pus rachetables pur anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles (pli sera tenue mardi, le 23 avril 1968, à 7.30 heures du soir.Bureau administratif dc la Commission Scolaire.I ISO.Boulevard Chainplain, Verdun, comté de Montréal-Verdun, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit dc n'accepter ni lu plus haute ni aucune des soumissions.Verdun, (Comté de Montréal-Verdun), ce 27 murs 19(is./.c secrétaire-trésorier, Paul Roy.Bureau administratif île la Commission Scolaire, 4-1S0, Boulevard Chain plu in.Verdun, (Montréal-Verdun), P.Q.Téléphone: 709-2771, code 514.24090-o Table of redemption \u2014 $725,000 \u2014 20 year.Year Capital Mav 1, 1969 .818,000 Ma'v 1.1970.19.000 Muv 1.1971.20.000 Mav 1, 1972.22,000 Mav 1, 1973.23,000 Mav 1, 1974.25.000 Mav 1, 1975.2(5.000 Mav 1.1970.28,000 Mav 1, 1977.30.000 Mav 1,1978.32,000 Mav 1, 1979.35.000 Mav 1,1980.37.000 May 1,1981.40,000 Mav 1, 1982.43.000 Mav 1,1983 .46,000 Mav 1,1981.49,000 Mav 1.1985.52.000 Mav 1, 1986 .56.000 Mav 1, 1987.00,000 May 1, 1988.61,000 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year .short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Verdun.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Quebec of the bank whosi name is mentioned in the loan procedure as well as at the head office of the said bank in Toronto.Ontario.The said bonds will not be redeemable bj anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1'\",' of the amount of tie present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their deliver.' is included or not in the price of the lender.The tenders will be opened and considered al a meeting of the School Commissioners to b held on Tuesday.April 23, 1968, at 7.30 o'clock, p.m., at the Administrative Ollice of the School Commission, 4480 Champlain Boulevard, Vci dun, county of Montreal-Verdun, P.Q.The school commissioners do not bind them selves to uccept the highest or any of the tenders Verdun, (County of Montreal-Verdun), Man 27.1908.Paul Roy, Secretary-Treasurer.Administrative Ollice of the School Commission, 4-180 Champlain Boulevard, Verdun, (Montreal-Verdun), P.Q.Telephone: 769-2771.code 514.210! Ville d'Anjou ( 'ointe dc Lafontaine Avis public est par les présentes donné quilles soumissions cachetées et endossées \u2022 Soumissions pour obligations * seront reçues par lu soussignée Mlle Colette Saucier, greffier, Hotel de Ville.6695, avenue Merrium.ville d'Anjou, comté de Lafontaine.P.Q.jusqu'à 5.30 heures de l'après-midi, lundi, le 22 avril 196S.pour Town of Anjou County of Lafontaine Public notice is hereby given that scale I tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will lie received by the undersigned Miss Colette Saucii .clerk.Town Hall, G695 Merriam Avenue, Town of Anjou, county of Lafontaine, P.Q., until 5:30 o'clock p.m., Monday, April 22, 1908, for the purchase of an issue of $1,500,000 of bonds QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 0, 1908, Vol.100, No.Ik 2227 l'achat do SI.500,000 d'obligations de la Ville for the town of Anjou, county of Lafontaine.d'Anjou, comté de Lafontaine, datées du 1er niai dated May 1, 1968, and redeemable serially 1968 et remboursables par séries du 1er mai 1969 from May 1, 1969 to May 1, 1988, inclusively, au 1er mai 1988 inclusivement, avec intérêt à with interest at a rate not less than 63 2%, nor 1111 taux non inférieur à 6,12%, ni supérieur a more than 7)4%, payable semi-annually on payable seini-aiiiuiellemcnt les 1er mai May 1st and November 1st of each year.The il 1er novembre de chaque année.Le taux rate of interest may be the same for the whole d'intérêt peut être le même pour toute rémission; issue; however a different rate of interest could, cependant un taux d'intérêt différent pourra en in addition to the initial interest rate, he accepted plus du taux d'intérêt initial être accepté dans in the case of bonds issued as ten-year short-term le cas des obligations émises à courte échéance or fiftcen-year short-term bonds, or as twenty- 10 ans ou 15 ans.ou terme fixe 20 ans.pourvu year fixed-term bonds, provided that the amounts que les montants ainsi émis, à ce taux différent, so issued, at such a différent rate, be for entire \u2022oient pour des échéances entières, en tenant maturities, bearing in mind the maturity tables compte du tableau d'échéances apparaissant dans appearing in this notice, le présent avis.Règlements Nos: 516-B - - 8273,500 \u2014 achat By-laws Nos.; 516-B \u2014 §273,500 \u2014 purchasing lie terrains; Ô47-A \u2014 837.000 \u2014 voirie; 63S of land; 547-A \u2014 $37,000 \u2014 roads; 638 (638-11) 1138-11) - $305.000 - - achat de terrains; 670-A \u2014 8305,000 \u2014 purchasing of land; 670-A 832.000- - voirie; 699 $12.000 - aqueduc, $32,000 \u2014 roads; 699 \u2014 $1^000 \u2014 aqueduct, ¦ _miiIs.718 \u2014 8155.500 \u2014 divers travaux d'unie- sewers; 718 \u2014 8155,500 \u2014 various local improve-orations locales; 721-A ¦ $200.000 achat de ment works; 721-A \u2014 8200.000 \u2014 purchasing of terrains; 721 SS5.000 divers honoraires land; 724 \u2014 885,000 \u2014 various professional fees: professionnels; 737 \u2014 $400,000 - aqueduc.737 \u2014 $400,000 \u2014 aqueduct, sewers.¦ goills.I'our adjudication seulement, l'intérêt sera For adjudication only, interest shall be calcu- ealculé à compter du 1er mai 1968.lated as from May 1, 1968.Tableau d'amortissement SI.500,000 \u2014 20 ans Table of redemption \u2014 $1,500,000 \u2014 20 years Annie\t\tCapital\tYear\tCapital 1er mai 1969\t\t$ 38,000\tMay 1, 1969\tS 38,000 1er mai 1970\t\t41.000\t\t 1er mai 1971\t\t43.000\tMav I, 1971\t43,000 1er mai 1972.\t\t47.000\tMav 1, 1972\t47,000 \t\t49,000\tMay 1, 1973\t49,000 1er mai 1974\t\t51.000\tMay 1, 1974\t51.000 1er mai 1975\t\t56.000\tMay 1, 1975.\t.56.000 1er mai 1976\t\t60,000\tMay 1.1976\t.60.000 1er mai 1977\t\t04.000\tMav 1.1977\t64,000 1er mai 197S\t\t68,000\tMay 1, 1978.\t68,000 1er mai 1979\t\t72.000\tMav 1.1979\t72 000 1er mai 19S0\t\t77.000\t\t 1er mai 1981\t\t82.000\tMay 1, 1981\t82.000 1er mai I9S2\t\t88.000\t\t88,000 1er mai 1983\t\t93.000\tMay 1, 1983\t93.00(1 \t\t100.000\tMav 1, 1984.\t100.000 1er mai 1985.\t\t107.000\tMay 1, 1985\t107.000 1er mai 1980\t\t114.000\tMay 1, 1986\t114.000 1er mai 1987.\t\t121.000\tMav 1, 1987\t121.000 1er mai 19S8\t\t129,001)\tMay 1, 1988\t129.000 De plus, des soumissions pourront être en- Moreover, tenders may be sent and shall be rayées et elles seront prises en considération considered us 10-year short-term or 15-year short-pour des obligations en séries à courte échéance terni bonds serially.Also, tenders shall he 10 ans ou à courte échéance lô ans.Egalement, received and considered as 10-year serial bonds ilea soumissions seront reçues et considérées pour with the balance partly 10-year short-term and des obligations cil series 10 ans avec le solde à partly 20-ycnr fixed-term bonds, provided, courte échéance 10 ans pour une partie- et l'autre however, that this latter part not be for less partie à terme fixe 20 ans.pourvu toutefois que than SI29,000, and, if higher than this latter (\u2022ctte dernière partie lie soit pas jwur un montant amount, this part must include only one or inférieur à S129.00O, et si supérieur à ce dernier more entire annual amortizations, while taking montant, cette partie devra comprendre qu'un into consideration the maturity tables appearing ou des amortissements aiiiiucls entiers, en tenant in this notice, beginning at the last years of compte 1I11 tableau d'échéance apparaissant dans maturity.However, tenders shall be sent for le présent avis, et cn commençant par les der- one of the above methods of issue only, ami shall nières années d'échéances.Cependant, les sou- include only one of the terms, save in the case missions ne devront être transmises que pour of the exception stipulated herein.Adjudication un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront shall be made according to law.comporter qu'un seul des ternies sauf duns le cas de l'exception notée.L'adjudication sera faite conformément a la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obliga- The successful tenderer agrees to pay for the lions, capital et intérêts courus s'il y a lieu, par bonds, principal and accrued interest, if any.chèque visé, payable au pair ù Anjou.by certified cheque payable at par at Anjou. 2228 GAZETTE OFFICIELLE DE QVEllEC.G arril IOCS.100' année, n' H Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales duns la province de Québec dc lu banque dont le nom est mentionné duns la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lcsditos obligations ne seront pu rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme lise 20 ans.pour un montant égal à 8129.000.Toutefois si elles sont émises cn partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 8129.0110.les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er mai de chaque année |x>ur le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tublcuu d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal ù 1% du montant «le l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Ix>s soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, lundi, le 22 avril 1068, à 5.30 heures de l'après-midi, Hôtel de Ville.8605, avenue Merriam.Ville d'Anjou, comté de Lafontaine.P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Anjou, (Comté de Lafontaine), ce 1er avril 1908.Le greffier.Colette Saucier.Hôtel de Ville.0090.avenue .Merriam.Ville d'Anjou.(Lafontaine).P.Q.Téléphone: 353-4440, code 514.24144-o Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Quebec of the bank whose name is mentioned in the loan procedure as well as at the head ollice of the said bank in Toronto.The said bonds will not be redeemable b\\ anticipation if they ure issued serially, or serially and as 20-yenr fixed-term bonds, for an amount equal to $129,000.However, if they arc issued partly as 20-year fixed-term bonds for un amount of more than $129,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on May 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice.Kneh tender must be accompanied by a certified cheque equal to [% of the amount of the issue, anil must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the lender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council lobe held on Monday, April 22.1908, at 5:30 o'clock p.m., at the Town Hall, 0095 Merriam Avenue, Town of Anjou, county of Lafontaine.P.Q.The council does not bind itself to uccept the highest or any of the lenders.Anjou, (County of Lafontaine), this April 1, 1968.Colette Saiiieu.Clerk.Town Hall, 6695 Merriam Avenue.Town of Anjou.(Lafontaine), P.Q.Telephone: 352-4 110.code 514.21141 < die dc Shaw inigun Comté de Saint-Maurice Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions DOW obligations i seront reçues par le soussigné Vvon Boisvert, greffier, Hôtel de Ville, rue des Cèdres, C.P.400, Shawiuigan.comté de St-Maurice.P.Q., jusqu'à 2 heures de l'après-midi, lundi, le 22 avril 1968.pour l'achat de 8028.500 d'obligations de la cité de Shawiuigan.comté de St-Maurice, datées du 1er mai 1968 et remboursables par séries du 1er mai 1969 au 1er mai 19S8 inclusivement, avec intérêt ù un taux non inférieur à (>.' 2r|.ni su|x'riour à 7}^'\"e- payable scmi-annuellemcnl les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant un taux d'intérêt différent pourra en plus du taux d'intérêt initial, être accepté dans le cas des obligations émises ù courte échéance 10 nus ou 15 ans.OU ternie fixe 20 ans, pourvu que les montants ainsi émis, à ce taux différent soient pour des échéances entières, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant duns le présent avis.Règlements nos: 940 $406.000 renouvellement; 1106 $67.800 voirie; 1122 \u2014 838.800 aqueduc, voirie; 1207 $58.900 aqueduc, égouts.voirie; 1218 - \u2022 8137.000 \u2014 achats de bâtisses et terrains; 1234 $220.000 fonds de roulement.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1968.Tableau d'amortissement S028.500 - 20 ans Année Capital 1er mai 1969 .$38.500 1er mai 1970 .41.000 1er mai 1971 43.000 City of Sliawinigan County of Saint-Maurice Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for Ixuuls\" will be received bv the undersigned, Yvon Boisvert, City Clerk.City Hall, des Cèdres St., P.O.Box 400, Shawinigan, count v of Sl-Mauricc.P.Q., until 2:00 o'clock p.m.Monday, April 22, 1968, for the purchase of an issue of $928,500 of bonds for the City of Shawinigan, county of St-Mnurice, dated May I.1968, and redeemable serially from May 1, 1969 to May 1.1988 inclusively, with interest at a rate not less than 6) i%.nor more thnn 7' ur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées a une «mi.c- publitpie qui sera tenue, lundi le 22 avril 1908.à 2 heures de l'après-midi.Hôtel de Ville, rue des Cèdres.C.P.400.Shawinigan.comté de St-Maurice.P.Q.Le conseil se réserve le droit dc n'ueeepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Shawiuigan.(Comté de St-Maurice).ce 28 mars 1908.Le greffier.Vvox BOfSVERT.Hôtel dc Ville, rue des Cèdres.C.P.400, Shawiuigan.(St-Maurice), P.Q.Téléphone: 537-1003, code 819.24095-O May 1,1972.$46,000 May 1, 1973 .48,000 May 1,1974.53.000 May 1, 1975.55,000 May 1,1976 .57,000 May 1,1977 .62,000 May 1,1978 .00,000 May 1,1979 71,000 May 1, 1980.74.000 Mav 1,1981.80.000 May 1, 1982 .38,000 May 1, 1983 .43.000 May 1,1984 20.000 May 1, 1985.22,000 May 1, 1986.22,001) Mav 1, 1987 .24.000 Mav 1, 1988 .25,000 Moreover, tenders may be sent anil they shall be considered as ten-year short-term or fifteen-year short-term serial bonds.Also, tenders shall be received and considered as ten-year serial bonds, with the balance being partly ten-year short-term and partly twenty-year fixed-term bonds, provided, however, that the latter part not be for less than 825.000, and.if higher than this amount, this part must include only one or more entire annual amortizations, taking into consideration the maturity tables appearing in this notice, beginning by the last years of maturity.However, tenders shall be sent for one of the above methods only, and shall include only one of the terms, save in the case of the exception stipulated herein.Adjudication shall In- made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any.by certified cheque payable at par at Shawinigan.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of said bank in Toronto, The said bonds will not l>c redeemable by anticipation if they are issued serially or serially anil as twenty-year fixed-term bonds for an amount equal to 825,000.However, if they arc issued partly as twenty-year fixed-term for an amount of more than $25,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on May 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice.Kach tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest acrrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened mid considered at a public meeting to lie held on Monday.April 22, 1968, at 2:00 o'clock p.m., in the City Hall, des Cèdres St., P.O.Box 400.Shawinigan.county of St-Maurice, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Shawinigan, (Countv of St-Maurice).March 28.1968.Vvox Bom vest, (Hi/ ( lark.City Hall, «les Cèdres St., P.O.Box 400, Shawinigan, (St-Maurice), P.Q.Telephone: 537-1003, code 819.24095 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 arril 1098, 100' année, n° 1A 2230 Mlle de Val d'Or ( 'imité d'Abitibi-Est Avis public est |)ar les présentes donné «pie «les soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues pnr le soussigné Albert Philibert, grellicr.Hôtel de Ville, 855.2e avenue.C.P.400.Val «l'Or, comté d'Abitibi-Est, P.Q.jusqu'à S 30 heures du soir, mardi, le 23 avril 1008.pour l'achat de 8430.000 d'obligations de la ville de Val d'Or, comté d'Abitibi-Est.datées du 1er mai 1908 et remboursables par séries du 1er mai 1909 au 1er mai 1988 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à O'/'i.ni supérieur à 7'^,'.payable semi-aiiniK llenient les 1er mai et 1er novembre île chaque année.I.e taux d'intérêt peut être le même |x>ur toute l'émission; cependant un taux «l'intérêt diffèrent pourra en plus du taux d'intérêt initial, être accepté dans le cas des obligations émises à courte échéance 10 ans ou 15 ans.ou terme fixe 20 ans.pourvu que les montants ainsi émise, à CC taux différent soient pour «les échéances entières, en tenant compte du tableau «1 echéaiu'i's apparaissant dans le présent avis.Règlements Nos: 372 \u2014 $70.000 \u2014 aqueduc et égouts; 422 8100.000 aqueduc et égouts; 42') SliO.OOO .'\u2022gouts et voirie; 428 890.0(H) \u2014 terrain de stationnement; 430 $50.000 \u2014 aqueduc; 4 19 $00,000 terrain de stationnement.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1908.Tableau d'amortissement - $.',.10,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 19119 .$11.0(10 1er mai 1070 .12.000 1er mai 1971.13.000 1er mai 1072.13.000 1er mai 1073.13.000 1er mai 1074.10.000 1er mai 197.) lii.ooo 1er mai 1070.ÎS.OOD 1er mai 1077.ls.ooo 1er mai 1978.19.000 1er mai 1979.22.000 1er mai 10SO.23.000 1er mai 1981.23.0(H) 1er mai 1982 .20.000 1er mai 19S3.28.000 1er mai 1984.29.000 1er mai 1085 .30.000 1er mai 1 DSC,.32.000 1er mai 1987.34.000 1er mai 1988.3.->.(HX> De plus.«l«-s soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations en séries à courte échéance 10 ans ou à courte échéance 15 ans.Egalement, des soumissions seront reçues et considérées |H)iir des obligations en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à ternie fixe 20 ans.pourvu toutefois «pie cette dernière parlie ne soit pas pour un montant inférieur à 135.000 et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra eonprenilre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échi'uncc apparaissant dans le présent nvis.et en commençant par les dernières années d'échéances.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans le cas de (exception notée.L'adjudication sera faite conformément à la loi.Town of Val d'Or County of Abitibi-East Public notice is hereby given that sealed ten dcrs endorsed \"Tenders for bonds\" will I received by the undersigned, Albert Philibert, town clerk.Town Hall, 855, 2nd Avenue.I'd Box 400.Val d'Or, count* of Abitibi-East, P.Q .until 8:30 o'clock p.m.Tuesday, April 23.1008, for the purchase of an issue of 8430.000 of bond for the town of Val d'Or, county of Abitibi-Eusl.ilateil May 1, 1908, and redeemable serially from May 1, 1909 to May I, 1988 inclusively, with interest at a rate not less than ()'/(.nor more than 7' \u2022/'(', payable semi-annually on May ]»' and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, a different rate of interest may.in add! tion to the initial rate of interest, be accepted in the ease of bonds issued as ten-year short-term or fiftcen-ycar short-term, or as twenty-year fixed-term, provided thai the amounts so issued, at such different rate, be for entire maturities, bearing in mind the table of maturities appearing in this notice.By-laws Nos: 372 \u2014 $70.000 - - aqueduct and Sewers; 422 - SIOO.000 - - aqueduct and sewer-.425 \u2014 800.000 sewers and roads; 428 \u2014 890.01 Hi \u2014 parking lot; 430 - - 850.000 - \u2022 aqueduct; 44'.' \u2014 $00,000 \u2022 \u2022 parking lot.For adjudication only, interest shall be calcu lated as from May 1, 190S.Table of redemption \u2014 S',30,000 \u2014 20 yean Year Capital Mav 1, 1909.$11.000 Mav 1.1970.12.000 Mav 1.1971.13.000 Mav 1.1972.13.000 Mav I.1973.13.000 Mav 1.1974.10.01)0 Mav 1, 1975.10.000 Mav 1.1970.18.000 Mav 1.1977.18.000 Mav 1.1978.19.000 Mav 1.1979.22.000 Mav 1.19S0.23.000 Mav 1.1981.23.000 Mav 1,1982.25.000 Mav 1,1983.28.000 Mav 1,1981.29.000 May 1, 1985.30.01)0 Mav 1, 1980.32.000 Mav 1.1987 .31.0(H) Mav 1, 198S.35.000 Moreover, tenders may be sent and shall be considered as ten-year sborl-tcrni or fifteen-short term serial bonds.Also, tenders shall be received and considered as ten-year serial bonds with the balance being ten-year short-lcrm foi the one part and twenty-year fixed-term for the other part, provided, however, that this latte: part not be for an amount less than 835,000, and.if higher than this latter amount, this part must include only one or more entire annual ainorli/.a lions, bearing in mind the table of nialiirilie appearing in this notice, beginning at the lust years of maturity.However, the tenders shall I» sent for one of the alxivc methods only, save in the ease of the exception stipulated herein.Adju dication shall be made according to law. GAZETTE OFFICIAI.GAZETTE, April fi*.IOCS, Vol.100.So.2231 L'adjudicataire s'engage a payer les obligation-,, eapilal el intérêts courus, s'il y a lieu, par i hèquc visé, payable au pair à Val «l'Or.I.e capital et les intérêts sont payable! A toutes I s succursales dans In province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'aux bureaux principaux de ladite banque à Toronto et à Ottawa.( Intario.Lcsditcs obligations ne seront pas rachetables [Xir anticipation si elles sont émises pur séries u eu -éries et ternie lixe 20 ans.pour un moulant égal il 830,000, Toutefois si elles sont émises cn partie à tenue lixe 20 ans pour un montant supérieur à $35.000 les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er mai de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de rémission, conformément au tableau d'échéances de l'émis- Ml apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée il un deque accepté égal à 1',' du montant de I ¦ mpriiiil et devra spécifier si le prix offert com-P vnd ou ne comprend pas les intérêts courus sur ! - obligations nu moment de leur livraison.I.cs soumissions seront ouvertes et considérées .une séance du cons dl qui sera tenue, mardi, le .'; avril IDiîS, à 8.31) heures «lu soir.H'did de Ville.855, 2c avenue.Cl\".101).Val d'Or, comté il'Ahilihi-F.sl.P.Q.I.e conseil se réserve le droit «le n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Val «l'Or.(Comté d'Abitibi-Est), ce 1er avril 1008.L$ greffier, Albert Piiiubebt.Ilr.lel de Ville.855, 2e avenue.C.P.400, Val d'Or (Abitibi-Est), P.Q.Téléphone: 824.0013, code 810.21112-0 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Vol d'Or.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the hea«l ollice of said bank in Toronto und Oltawa, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and as twenty-year fixed-term bonds, for an amount equal to 835,000.However, if they are issued partly as twenty-year fixed-term for an amount of more than 833.000, the bonds so issue I will be redeemable by anticipation, at par.on .May 1st of each year lor the annual required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to lr,' of the amount f the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is include I or not in the price of the tender.The lenders will be opened and considered at a meeting ol the council to be held on Tuesday, April 23.1008, at 8:30 o'clock p.m., in the Town Hall, Sl.'>.2nd Avenue.P.O.Box 100, Val d'Or, county of Abitihi-lv'.-l.P.Q.The council does not bind itself lo nccepl the highest or any of the tenders.Val d'Or, (County of Abitibi-East), April 1, 190S.Albert Philibert, Toirn Cleric.Town Hall, So\").2nd Avenue.P.O.Ilox 100.Val d'Or (Abitibi-East), P.Q.Telephone: 824-0013, code 811).2-1112 Vente «IVflVls non-reclaim's Messageries Canadien Pacifique Avis est par les présentes donné que tous les effets rcc,us avant le 1er jour de mai 1007, et non reclames aux bureaux des Messageries Canadien Pacifique, à divers endroits de la province de Québec, seront vendus aux enchères publiques au plus haut enchérisseur par Frank Wadiliiigton, enianleiir.128 est, rue King, Toronto.Ontario, à ONZE heures du matin, le DEL'XIÊME jour «le MAI 100S.à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.Québec, Que.le 1S mars 1 DOS.Lu Cic des Messageries Canadien Pacifique.Le surintendant général, 23928-12-6-0 E.M.Tiiiiasiier.Sale* «f \\ itelaimeil Bagage Canadian Pacific Express Company Notice is hereby given that all goods received previous to the first day of May 1007, and still remaining unclaimed in the offices of the Canadian Pacific Express Company, at different points in the Province of Quebec, will be sold at public auction to the highest bidder by Frank Wadding-ton, Auctioneer, at 128 King Street East, Toronto, Ontario, at ELEVEN o'clock in the forenoon, on the SECOND day «>f MAV 1008.unless same shall lie called for before that date and all charges paid thereon.Quebec, (inc.March 18th.1008.Canadian Pacific Express Company.E.M.TuitAsiiF.n.2392S-12-6-0 General Superintendent.Ventes pour taxes Cité de Chicoutimi Avis public est par les présentes donné par le soussigné, grellicr «le la susdite municipalité, que les propriétés ci-après «h;crites seront vendues à l'enchère publique cn la salle des délibérations du conseil, à l'Hôtel dc Ville de la cité de Chicou- li.ni.MERCREDI, le VINGT-QUATRIÈME jour d'AVRIL 100S.ù DIX heures de l'a van t-midi, pour satisfaire nu paiement des taxes «lues à la cité de Chicoutimi et à la Commission des Ecoles Catholiques de Cliieoiitiiui, avec les intérêts et les frais plus les frais suhséqiicmmcut encourus, à moins que lesdites taxes, les iutéréts et les frais ne soient puyés avant la vente.Sales for Taxes City of Chicoutimi Public notice is hereby given by the undersigned, clerk of the aforesaid municipality, that the property hereafter described will lie sold, by public auction, in the meeting hall of the council, at the Town Hall of the « ilv of Chicoutimi, WEDNESDAY, the TWENTY-FOURTH day of APRIL.190S.at TEN o'clock in the morning, to satisfy the payment of taxes due to the city of Chicoutimi and to the Catholic School Commission of Chicoutimi, with the interests ami costs, plus the costs subsequently incurred, unless the said taxes,\" interests and costs shall have been paid before the sale. 22.32 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, C, arril 1968, 100' année, n° 1A Noms dos propriétaires Names of proprietors Numéro des lots et cadastre Number of lots and cadastre Description contenue dans ncte d'enregistrement No Description contained in registration deed No.Auclair, Joan-Charles.1592.St-lRnaco.Beaulioii.ClaUde.412, Cnudreault.Bédnrd, Henri, 'Kill.Viliiiond.n/i.Léonce.BOO, Doquon.Bédnrd, Mmc-Mrs.Léonce, uéo-born Patricia Boily.4.84.Ijéservo.Bélanger, Chs-Édouard, 70G.Taché.Bender.Patrick, rue Chopin Street.Boui hard, Jcnii-Bnpt istc, 15-17.Cascades.Brassard, liomiiald, 1(111, Lavoio.Coté, Denis, 501, Lcgrmid.Couturier.J.A.392, Labrceque.DcselicMies, Léo, 5-1!), Délace.Dufour, J.Raymond ot-and Léon-Pierre, rue Montcalm Street.I'orlin, Nil, 107, Crémazic.Foster, J.-Baptisto, 012, Réserve.(inRiian, Lionel.'17.William.(ïnutliier, Léon-Georges, 295, Labreequc.Gauthier.Marcel, 12S, Jacques-Cartier B.Girard-Cloulier, Mauriee ct-and Martial Naull, 27-20, Priée.Quay, Ovllo, 023, Logmnd.Gutiy, Ovllo, 1023.Jolliét.Hovillgton, J.-Henri, .Stc-Annc.P.0-B, r.14, S.O.C.S.par.do-of Chicoutimi P.115, P.117, ville dc-town of Chicoutimi.111!)-'.), 1121-4, ville dc-town of Chicoutimi.lll'J-S, 1121-8, ville do-town of Chicoutimi.P.1121, ville dc-town of Chicoutimi.P.880-1!).SS'J-10.800-30, ville dc-town of Chicoutimi.1-B-IO.r.8.8.O.C.S., par.(Ic-of Chicoutimi.000-0, ville dc-town of Chicoutimi.3-A-1S, r.15.S-O.C.8., par.de-of ClÙCOUtimi 1133-7, ville dc-town of Chicoutimi.101-45, ville dc-town of Chicoutimi.P.839, ville de-town of Chicoutimi.Immeubles Lnnncé Lifo, Boulevard Talbot.Lajoio, Mmo-Mrs.Alfred.434, Dréan.Lavoie.Gérard, 100, Itônnkl.Lavoio.Mino-Mis.J.-Baptiste, iiée-lx>rn Itoso-Ahiin Bouchard, 284.Késerve.Lavoie.Ls-Ifcnii, 004, Lavoie.Lavoio.Ls-Ifeiiri, rue Lavoio Street.Lavoio, Ls-llenri, rue Lavoie Street.Lavoio, Lg-Honri, rue Lavoie Street.Lessard, Mme-Mrs.Julien, I4lili, Sl-Ignacc.Maltais, Jean-Mario, rue Taillon Street.Martel, Polis, 1830, St-Ignace.Martel, François, ruo Désaligné Street.Morill, Louis-Henri, ruo Albert Street.Miirin, Louis-Hciu i, SI, Allicrt.Picard, Robert, 443, do Tilly.Picard, Hobort.rue J.Cartier E.Street.Poil l'a.-., Mme-Mrs.Cilles, née-boni Yolande l'inouull, ruo Louis-Frai coeur Street.Poitras, Mmo-Mrs.Cilles, uéo-born Yolande Piucaiili, 3d, Si-Hubert.Poitras, J.-Adrieii, 420, J.-Carlier E.Ringuotte, Alfred, ruo Desgagné Street.Savard, Charles, ruo Dorval Street.Savard, Charles, ruo Dorval Street.Savard, Charles, Avenue Lcgnind Avenue.Savard.Mme-Mrs.Vincent, néo-born Jeannette Lapointe, 434, do Tilly.Savard, Mme-Mrs.Vincent, néo-born Jeannette Lapointe, 1080, Marquette.Siniard, Fernand.Avenue Lcgrand, Avenue.Biinara, Mmo-Mrs.J.-Baptisto, néo-born Carmen Tremblay.Tremblay, Jeun-Marie, 124.des Oblats.Tremblay, Joan-Paul ot-aiid J.-B.-A.Guriioii, 215 Price ouest-west.Tremblay, Jos.-Emile, 4lti, Laurier.Tremblay, Léo, 105S, Lavoio.Tremblay, Lucien.329.Le Doré.Tremblay, Danio Olivette, 41S, Réserve____ Ti m bon, Jacques.840, St-Paul.Truobon, Joseph.213, Bossé.Voohon, Roger, rue Ste-Monique Street.Aube, Mme-Mrs.Gédeon, néo-born Marie-Ange Laroueho, sso, Réserve.Un terrain connu et désigné cnnmic étant une parlie des lots Nos 1137 et 1138 du cadastre officiel de la ville de Chicoutimi, mesurant environ 100 pieds dc largeur du nord-est au sud-ouest par environ 200 pieds dc profondeur et compris dnns les bornes suivantes: nu sud-est h la rue St-lRiiaee; nu sud-ouest i\\ Adéhird Blackburn ou représentants; nu nord-ouest et au nord-est i\\ Théodule Tremblay ou représentants.Sauf ù 726-0,1187-1, ville do-town of Chicoutimi.040-52, ville dc-town of Chicoutimi.P.11-12, P.1135, ville dc-town of Chicoutimi 570-1, ville de-town of Chicoutimi.P.ISO, ville dc-town of Chicoutimi.305-2-1, 1223, ville dc-town of Chicoutimi.40S-1-A, 408-2, ville de-town of Chicoutimi.1145-15, ville dc-town of Chicoutimi.087-7, ville de-town of Chicoutimi.P.1008-3, P.1109-1.ville de-town of Chicoutimi.70-101, r.1.S.O.C.S., par.do-of Cliicoutiiui P.lioi, ville dc-town of Chicoutimi.S70-23, ville de-town of Chicoutimi.P.1042, P.1059, ville dc-town of Chicoutimi 2-B-24, r.15, S.O.C.S., par.dc-of ( liieouiimi 2-11-25, r.15.S.O.C.S.par.do-of < hi.-oul imi 2-B-20, r.15, S.O.C.S., par.dc-of Chicoutimi 2-B-27, r.15, S.O.C.S., par.do-of Chicoiii imi 5-B-31-2.5-B-00, r.14, S.O.C.S., par.dc-of Clilcuutlini.0-B-7, r.S, S.O.C.S., par.do-of Chicoutimi.P.7-C,r.14.S.O.C.S., par.do-of Cliicoutiiui l-B-93, r.Il, S.U.t '.S., par.de-of Cliicoutiiui l-tl-73, r.15, S.( I.C.S., par.de-of Chicoutimi l-C-07, r.15, S.O.C.S., par.dc-of Cliicoutiiui 71-A-0-130, r.1, N.E.C.S., par.de-of Chicoutimi.P.302.P.303.ville do-twoii of Chicoutimi.3-B-3G3, r.8.S.O.C.S.par.dc-of Chicoutimi P.502-0, ville dc-town of Chicoutimi.P.121.P.121-A.ville dc-town of Chicoutimi P.2-C, r.14, S.O.C.S., par.dc-of Chicoutimi 1155-1-10.1157-1-1.1157-1-5, ville dc-town of Chicoutimi.1155-1-0, ville de-town of Chicoutimi.1155-1-8, ville do-town of Chicoutimi.71-A-fi-I45.r.1.N.E.C.S., par.dc-of Chicoutimi.097-31 099-3.ville do-town of Chicoutimi.1144-11, 1145-0, ville dc-town of Chicoutimi 4-31.r.9, S.O.C.S., par.do-of Chicoutimi.073-2, ville dc-town of Chicoutimi.P.70S, P.709, ville do-lown of Chiroutiini.P.470, P.471, ville de-town of Chicoutimi.3-A-15.3-A-17.r.15, S.O.C.S., par.do-of Chicoutimi.P.820, P.821, P.11S7, ville dc-town of Chi- tiini.Jii ind.P.111.P.1122, ville dc-town of Chicoutimi.1172-30, ville dc-town of Chicoutimi.P.731, P.733, ville do-town of Cliicoutiiui.P.2-B.r.15, S.O.C.S.par.de-of Chicoutimi 143,053 1 7S.lL\".) 140,491 153,097 205.547 91,371 103,084 153,590 141.1S2 31,001 190,855 73.900 191,107 197.S01 123.S12 121.9S3 212,005 151,525 I20.2SI 205,759 180.005 170,590 A piece of land known and designated as being a part of lot Nos, 1137 and 113S of the oflieial cadastre of the town of Chicoutimi, measuring approximative^ 100 foot in width from the northeast to the southwest by approximativcly 200 foot in depth and included in tlie following boundaries: on the southeast by St-Ignacc Street: on the southwest by Adélard Blackburn or representatives; on the northwest and northeast b) QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April fi, 1968, Vol.100, No.1J, 2233 distrain les terrains vendus pnr Gédéon Aubé A Laurent .fORDEN S.YOLLES No 743 850.\u2022 1VA et al, (M.S.Voiles ' & Associates), demandeurs, MACE DEVELOPMENT LTD., défenderesse.Les lois originaux numéros mille trois cent neuf, mille trois cent vingt-deux, mille trois cent vingt-trois, mille trois cent dix-huit, mille trois cent vingt et un et mille deux cent quotre-iiigt-dix-sept A (1319.1322.1323.1318.1321.1297-A) aux plan et livre de renvoi officiels du n lie- St-Anloine de la cité de Montréal: Les subdivisions deux, trois, quatre, sept, neuf.dix.onze, douze, treize, quatorze, oi.iii/e.seize et dix-sept du lot originaire numéro mille trois cent huit (1308-2, 3, 4, 7, 8.9, 10.12.13.14, 15, 16 et 17) BUX plan et livre dc i\\oi ollieiels du quartier St-Antoine; La portion sud-est du lot numéro mille Il lis cent vingt (S.E.Plie lot 1320) aux plan Pl livre de renvoi ollieiels du quartier St-Antoine, lin surant vingt-cinq pieds île largeur sur une profondeur de quatre-vingt-quinze pieds et neuf es.bornée cn front par l'avenue Collège M> ' ¦ ill.eu arrière par une ruelle, d'un ciMé au '.d-ouest par le résidu dudit lot mille trois i vingt et île l'autre côté au sud-est par le mille trois cent vingt et un; La portion nord-ouest du lot numéro mille trois cent vingt-quatre (N.O.Plie lot 1324) aux i ii cl livre de renvoi ollieiels du quartier St-vitoïne, mesurant dix-sept pieds et quatre-¦ wgt-quinze centièmes d'un pied de largeur cn front et dix-sept pieds et quatre-vingt-seize 1 enhèmea d'un pied de largeur cn arrière sur une profondeur quatre-vingt-quinze pieds et neuf pouces, bornée en front par l'avenue Collège Fieri Facias de Terris Superior Court \u20141 District of Montreal Montreal, to wit: | \\ /fORDEN S.YOLLES No.743 850.< 1V1 el ai.(M.S.Voiles ' & Associates), plaintiffs, rs MACE DEVELOPMENT LTD.defendant.(a) Original lots numbers one thousand three hundred and nineteen, one thousand three hundred and twenty-two.one thousand three hundred and twenty-three, one thousand three hundred and eighteen, one thousand three hundred and twenty-one and one thousand two hundred and ninetv-seven A (1319, 1322.1323, 1318.1321.1297-A) on the ollieial plan and book of reference of the St.Antoine Ward of the city of Montreal: (b) Subdivisions two.three, four, seven, eight, nine.ten.eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen and seventeen of original lot number one thousand three hundred and eight (1308-2.3.4.7.8.0.10.11.12.13.14.15.16 and 17) on the ollieial plan and book of reference of the St.Antoine Ward; (c) The southeasterly portion of lot number one thousand three hundred and twenty (S.E.Pt.lot 1320) on the ollieial plan and book of reference of the St.Antoine Ward, measuring twenty-five feet in width by a depth of ninety-five feet and nine inches, bounded in front by McGill College Avenue, in rear by a lane, on one side to the northwest by the residue of the said lot one thousand three hundred and twenty, and on the other side to the southeast by lot number one thousand three hundred and twenty-one; (our l'élargissement de la rue Burnside; e) Un emplacement ayant front sur la rue Victoria en lu ville de Montréal, connu et désigné comme étant le tiers sud-est du lot numéro treize cent neuf (S.E.1/3 1309; aux plan et livre de renvoi ollieiels du quartier St-Antoine, mesurant dix-huit pieds et huit pouces de largeur en front et à l'arrière, sur la profondeur entière dudit lot borné en front par ladite rue Victoria, au nord-ouest par le résidu dudit lot treize cent neuf, au sud-est par la subdivision dix-sept «lu loi treize cent huit et en arrière par une ruelle; «d avec le droit dc passage en commun avec les autres ayant droit dans la ruelle en arrière; f) Ce certain emplacement ayant front sur l'avenue Collège McGill en la ville de Montréal, Connu et désigné comme étant la partie nord-ouest du lot numéro treize cent vingt (N.O.ptic 1320) aux plan et livre île renvoi officiels du quartier St-Antoine de la ville dc Montréal, mesurant sur le sol soixante pieds cl quutrc-vingt-trois centièmes d'un pied dc largeur cn front, soixante et un pieds île largeur en arrière sur une profondeur de quatre-vingt-quinze pieds et sept dixièmes d'un pied sur sa ligne de côté nord-ouesl cl quatre-vingt-quinze pieds et quatre-vingt-neuf centièmes d'un pied sur su ligne sud-est, mais suivant l'acte du titre de propriété, soixante et un pieds de largeur cn front et à l'arrière et quatre-vingt-seize pieds et trente-trois centièmes d'un pied de profondeur, borné en front au sud-ouest par l'avenue Collège McGill, Ctl arrière au nord-est par une ruelle, d'un Côté au nord-ouest par le lot numéro treize cent dix-neuf auxdits plan et livre dc renvoi ollieiels, et de l'autre côté au sud-est jMir le résidu dudit lot numéro treize cent vingt.g) Ce certain emplacement ayant front sur la rue Victoria, en la ville de Montréal, faisant partie du lot numéro douze cent quatre-vingt-dix-sept (ptic 1297) aux plan et livre de renvoi ollieiels du quartier St-Antoine, mesurant vingt-deux pieds et huit pouces de largeur sur une profondeur de quatre-vingt-quinze pieds, six pouces et borné en front par la rue Victoria, cn urrière par une ruelle et des deux côtés par d'autres parties dudit lot douze cent quatre-vingt-dix-sept, la ligne de côté sud-est de la propriété étant parallèle et distante dc vingt-deux pieds et huit pouces de la ligne de côté nord-ouest de la subdivision « A » dudit lot douze cent quatre-vingt-dix-sept ; h) Ce certain emplacement ayant front sur la rue Victoria en la ville de Montréal, connu et désigné comme étant la portion sud-est du lot numéro treize cent dix (S.K.ptic 1310) aux plan et livre de renvoi ollieiels du quartier St-Antoine, mesurant sur le sol vingt-huit pieds et quatre dixièmes d'un pied dc largeur sur une profondeur de quatre-vingt-seize pieds et cinq dixièmes d'un pied, borné en front au nord-est par la rue Victoria, cn arrière au sud-ouest par une ruelle, d'un côté au sud-est par le lot numéro treize cent neuf, et île l'autre côté nu nord-ouest par le résidu dudit lot numéro treize cent dix; i) Ce certain emplacement ayant front sur la rue Victoria cn la ville de Montréal connu et désigné comme étant la portion sud-est du lot Avenue, in rear by a lane, on one side to thi northwest by lot one thousand three hundrci and twenty-three and on the other side to tin southeast by the residue of said lot one thousani three hundred and twenty-four, the said rcsidui having been expropriated for the widening of Burnside Street; (e) An emplacement fronting on Victor! Street in the City of Montreal, known aie designated as the southeast third of lot numbc thirteen hundred and nine (S.E.1/3 1309) oi the ollieial plan and book of reference of Ihe Si Antoine Ward, measuring eighteen feet and eight inches in width in front and in rear, by tic full depth of said lot bounded in front by sail Victoria Street, to the northwest by the residir of said lot thirteen hundred and nine, to tin southeast by subdivision seventeen of lot thirtcei hundred and eight and in rear by a lane; and with the right of passage in common with all others having rights therein in the lane in the rear.(/) That certain emplacement fronting on McGill College Avenue in the city of Montreal known and designated as being the northwest pari of lot number thirteen hundred and twenti (N.W.Pt.1320) on the official plan and l>ook of reference of the St.Antoine Ward of the city ol Montreal, measuring on the ground sixty feel and eighty-three hundredths of a foot in width in front, sixty-one feet in width in rear, by n depth of ninety-five feet and seven-tenths of ,i foot in its northwest side line and llincty-fivc feet and eighty-nine one-hundredtbs of a fool in its southeast line, but according to the title deeds, sixty-one feet in width in Iront and in rear and ninety-six feet and thirty-three huuilredlh-of a fool in depth, bounded in front to the south west by McGill College Avenue, in rear to tic northeast by a lane, on one side to the north west by lot number thirteen hundred and nine teen Oil the said ollieial plan and book of reference and on the other side to the southeast by tin residue of said lot number thirteen hundred and twenty.(y) That certain emplacement fronting oi Victoria Street in the city of Montreal, being part of lot number twelve hundred and ninclx seven (Pt.1207) on the official plan and lx>ol.of reference of the St.Antoine Ward, measurii twenty-two feel eight inches in width by a dcpl of ninety-live feet, six inches, and bounded i front by Victoria Street, in rear by a lane and on both sides by other parts of said lot twel\\ hundred and niiiely-scven.the southcastcrl.side line of the property being parallel and di-tunt twenty-two feet eight inches from th northwesterly side line of subdivision \"A\" of said lot twelve hundred and ninely-seveii; (h) That certain emplacement fronting o Victoria Street in the city of Montreal, know and designated as the southeast portion of h number thirteen hundred and ten (S.E.Pt.1311 on the ollieial plan and book of reference of li St.Antoine Ward, measuring on the groui I twenty-eight feet and four-tenths of a foot i width by a depth of ninety-six feet and li\\ tenths of a foot, bounded in front to the northeast by Victoria Street, in rear to the southwi by a lane, on one side to the southeast by |i i number thirteen hundred and nine, and on tic other side to the northwest by the residue of t' i' said lot number thirteen hundred and ten ; (i) That certain emplacement fronting i Victoria Street in the city of Montreal, know n and designated as the southeasterly portion >f QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, April B, 1968, Vol, h\"*.No./; 2243 numéro treize cent neuf (Ptie 1309) aux plan et livre «le renvoi officiels du quartier St-Antoine, mesurant dix-huit pieds et huit pouces de largeur sur une profondeur dc quatre-vingt-quinze pieds et six pouces conformément aux actes du titre de propriété mais ayant une profondeur de quatre-\\ingt-scizc et cinq dixièmes d'un pied, conformément à un plan préparé par I.cmicux & Té-treaidt, nrpenteurs-géomètres du Québec, cn dale du treizième jour d'août, dix-neuf cent soixante-quatre, borné en front au nord-est par la rue Victoria, cn arrière au sud-ouest par une ruelle, d'un côté nu nord-ouest par le résidu dudit lot treize cent neuf, et «le l'autre côté au sud-est |»ar la subdivision dix-sept du lot numéro treize cent huit; lot number thirteen hundred and nine (Pt 1309; on the ollieial plan and l>ook of reference of the St.Antoine Ward, measuring eighteen feet eight inches in width by a depth of ninety-five feet six inches according to the title deeds but having a depth of ninety-six feet and five-tenths of a foot according to a plan prepared by l.einieux & Tétreault.Quebec Land Surveyors, dated the thirteenth day of August, nineteen hundred and sixty-four, bounded in front to the northeast by Victoria Street, in rear to the southwest by a lane, on one side to the northwest by the residue of said lot thirteen hundred and nine, and on the other side to the southeast by subdivision seventeen of lot number thirteen hundred and eight-.j) Ce certain emplacement ayant front sur (j) That certain emplacement fronting on l'avenue Collège McGill en la ville de Montréal.Metiill College Avenue in the city of Montreal, connu et désigné comme étant une partie du lot known and designated as a part of lot number numéro treize cent vingt (Ptie 1320) aux plan et thirteen hundred and twenty (Pt.1320) on the livre de renvoi ollieiels du quartier St-Antoine, ollieial plan and book of reference of the St.mesurant sur le sol vingt-six pieds de largeur en Antoine Ward, measuring on the ground twenty-front et vingt-cinq pieds et soixante-quinze six feel in width in front ami twenty-five feet centièmes d'un pied dc largeur cn arrière sur une and seventy-five hundredths of a foot in width profondeur de quatre-vingt-quinze pieds et in renr by a depth of ninety-live feel and seventy-s.iixuutc-quin/.c centièmes d'un pied sur sa ligne five hundredths of a fool in its northwesterly nord-Ouest et quatre-vingt-seize pieds et cin- line and ninety-six feet and fifty-four hundredths qiiaute-quatrc centièmes d'un pied sur sa ligne of n foot in its southeasterly line, bounded in sul-est, borné cn front nu sud-ouest par ladite front to the southwest by said McGill College avenue Collège McGill, en arrière au nord-est Avenue, in rear lo the norl beast by a lane, and Oil par une ruelle, et des deux côtés par d'autres both rides by other parts of said lot number parties dudit lot numéro treize cent vingt, la thirteen hundred and twenty, the northwesterly ligne nord-ouest dudit emplacement étant parai- line of said emplacement being parallel ami Nie et distante de soixante pieds et cinq dixièmes distant sixty feel and five-tenths of a foot, d'un pied, approximativement, de lu ligne sépa- approximately, from the line of division between r.ilive entre ledit lot numéro treize cent vingt ct said lot number thirteen hundred and twenty le lot treize cent dix-neuf, mesurés dans une ond lot thirteen hundred ami nineteen, measured direction sud-est; i\" a southeasterly direction; It) Cc certain emplacement ayant front sur (*) That certain emplacement fronting on la rue Victoria en la ville de Montréal, connu et Victor» Street m the city of Montreal, known dé-igné comme étant la tierce partie centrale cc, défenderesse, et JAMES W.DOWNING, régistrateur du bureau d'enregistrement de la division de Stanstead, Stanstcad Plain, dits district et province, mis-cn-causc.« 1.Un immeuble connu et désigné comme étant: L'emplacement ci-après décrit sans les bâtisses: 1.Ces certains lots de terre connus et désignés sur le plan officiel du cadastre et dans le livre de renvoi pour le village dc Rock Island, comme étant les lots numéros soixante-quatorze, soixante-quinze (74.75) laquelle propriété était autrefois connue sous le nom de Rock Island House, maintenant * Del Monty Hotel », sauf et excepté cette certaine partie dudit lot soixante- 3uinzc (Pt 75) vendue à la municipalité du village c Rock i .land pour redresser le chemin conduisant à Stanstcad Plain et étant une lisière dc terre d'une longueur de trois cent cinquante pieds (350') variant cn largeur de un pouce (1\") à sept pieds (7') sujet à toutes les servitudes actives et passives affectant ladite propriété et plus spécialement â certains droits dc passage pour se rendre à ladite propriété et aux propriétés et bâtisses dessus construites; 2.Une certaine partie du lot numéro soixante-treize (Pt 73) sur le plan officiel du cadastre et clans le livre dc renvoi pour ledit village de Rock Island, bornée à l'ouest par Riverside Avenue, à l'est par la rivière Tomifobia, au sud par la propriété ci-dessus décrite et au nord par une ligne droite partant dc Riverside Avenue allant jusqu'à ladite rivière Tomifobia, parallèle à la ligne de la propriété décrite en premier lieu et à une distance de soixante et un pieds (61') et deux pouces et demi dc ladite ligne et passant et touchant juste au coin nord-est de la maison actuellement construite sur ladite propriété, sujet aux droits en commun à un espace de terrain de trois pieds (3') environ entre la propriété vendue et la propriété voisine appartenant k Dame Margaret Lcpitre ou représentants et à certains droits dc vue et autres servitudes plus au long décrits dans le titre d'acquisition des vendeurs.» Avec bâtisses dessus construites et les améliorations sur ledit immeuble.Les droits de International Water Company consistant plus spécialement dans le droit de passer un tuyau pour l'eau sur le terrain présentement vendu le tout tel qu'il existe actuellement, cn vertu d'une servitude enregistré le 29 juillet SAINT\u2014FRANCIS Fieri Facias de Terris District of Saint Francis (Sherbrooke) Provincial Court, I TOWN OF ROCK IS-No.6611.\\ 1 LAND, a municipal l corporation, duly constituted, having its head office in the town of Rock Island, said district and province, plaintiff, r» NIRDAC INC., a body politic and corporate, liaving its chief place and principal seat of business at 201.2nd Avenue.Limoilou.district of Quebec, defendant, and JAMES W.DOWNING, registrar of the Stanstcad division registry office, Stanstead Plain, said district and province, mis-en-cause.\"1.An immovable property known and designated as being: The emplacement hereinafter described without buildings: 1.These certain lots of laud known and designated on the official cadastral plan and on the book of reference for the village of Rock Island as being lots numbers seventv-four.seventy-five (74.75), which property used to he known under the name of Rock Island House, and now as \"Del Monty Hotel\", save ami except this certain part of said lot seventy-five (Part 75) sold to the municipality of the village of Rock Island to straighten the road leading to Stanstcad Plain and being a strip of land having three hundred and fifty feet (350') in length and the width of which varies from one inch (1\") to seven feet (7') subject to all servitudes active and passive affecting tlic said property and more particularly certain rights of way to reach the said property and the properties and building-thereon erected; 2.A certain part of lot number seventy-three (Pt 73) on the official cadastral plan and on the book of reference for the said village of Rock Island, bounded on the west by Riverside Avenue, on the cast by the Tomifobia River, on the south by the hcreabovc described property and on the north by a straight line going from Riverside Avenue up to the said Tomifobia River, parallel to the limit of the first described property and being at a distance of sixty-one feet (61') and two and one half inches from the said limit and passing and touching to the northeast corner of the house now erected on the said property, subject to rights with others to a piece of land of about three feet (3') between the sold property and the neighbouring property belonging to Dame Margaret Lepilre or representatives and to certain rights of view and other servitudes described with more details in the vendors' title of property.\" With buildings thereon erected and improvements on the said immovable.The rights of International Water Company consisting more specifically in the right to put up a watcrpipe on the land now being sold, the whole as it now exists, pursuant to a servitude regi-tered on July 29, 1911, under number B 47,13145 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.U 2247 1911 sous le numéro B, 47.13145 sauf et excepté partie du lot soixante-treize (pt 73) vendue à M.Boissy et décrite dans une quittance et mainlevée enregistrée sous le numéro 16163 et sauf et excepté partie du lot soixante-quinze (Ptie 75) vendue à la municipalité de Rock Island et décrite dans un acte de vente enregistré sous le numéro 66869.Avec bâtisses dessus construites circonstances et dépendances et avec un mur de soutènement.» Pour être vendus « en bloc » au bureau d'enregistrement, à Stanstead Plain, comté de Stanstead, MARDI, le SEPTIÈME jour de MAI 1968, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Donat Jacques.Palais de Justice, Sherbrooke, le 1er avril 1968.24146-0 save and except part of lot seyenty-three (Pt 73) sold to Mr.Boissy and described in a discharge and withdrawal registered under number 16163 and save and except part of lot seventy-five (Pt 75) sold to the municipality of Rock Island and described in a deed of sale registered under number 66869.With buildings thereon erected, circumstances and dependencies and a retaining wall.\" To be sold \"en bloc\" at the registry office at Stanstead Plain, county of Stanstcad, on TUESDAY, the SEVENTH day of MAY, 1968, at TEN o'clock in the forenoon.Donat Jacques, Sheriff's Office.Sheriff.Court House, Sherbrooke, April 1st, 1968.24146 INDEX No 14 ARRÊTÉS en Conseil ORDERS in Council 122 \u2014 Alimentation au détail.Québec (Erratum).2205 122 \u2014 Food, Retail, Quebec (Erratum).2205 661 \u2014 Impôt sur les corporations, et la déduction des dividendes dans le calcul des profits.2209 061 \u2014 Corporation Tax Act, and the deduction of dividends in computing profits.2209 736 \u2014 Révocation des droits de mine autres que l'or et l'argent sur certains terrains situés dans le canton de Lingwick, district électoral de Compton.«206 736 \u2014 Revocation of mining rights other than the gold and silver found on certain pieces of land situated in the township of Lingwick, electoral district of Compton.2206 807 \u2014 Boites de carton ondulé, province.2206 807 \u2014 Corrugated Paper Boxes, Province.2206 810 \u2014 Construction (Calorifugeurs) Montréal.2205 810 \u2014 Construction (Asbestos Insulation Trade) Montreal.2205 811 \u2014 Imprimerie, Montréal.2208 811 \u2014 Printing, Montreal.2208 ASSOCIATION Coopérative COOPERATIVE Association Association coopérative de téléphone de Valcourt (Ch.statut).2211 AVIS divers MISCELLANEOUS Notices Bcjeck, Manfred Klaus (Acc.-Grant.).2193 ( aulct, Joseph Grégoire Philippe André (Acc.-Grant.).2194 Caulet.Joseph Jean-Baptiste Réjean (Acc.-Grant.).2194 Chevaliers de Colomb de Chandler inc.Conseil Mgr.Ross No 3261.2194 ( hevaliers de Colomb de Dante, Conseil No 3479 (Régi.).2215 ( ondax, Dem (Acc.-Grant.).2194 ( 'orporation des Techniciens Professionnels de la province de Québec (Erratum).2196 < orporation of Professional Technicians of the Province of Quebec (Erratum).2196 De Brienne, Joseph Armand Leenel Bernard (Acc.-Grant.).2194 Erlich.Michael (Acc.-GraiU.).2194 Fournier, Joseph Roger Claude (Acc.-Grant.).2194 Hart.Paul (Acc.-Grant.).2195 Knights of Columbus of Chandler Inc., Council Msgr.Ross No.3261.2194 Knights of Columbus of Dante, Council No.3479 (By-laws).2215 Krane, Murray (Acc.-Grant.).2195 Mastro, Dominic (Acc.-Grant.).2195 Si-Hubert, ville-town.2196 Saleh, Maurice (Acc.-Grant.).2195 Shelley, Charles Ivan (Acc.-Grant.).2195 Sherwood, Robert Steiner (Acc.-Grant.).2195 Smart, Max (Acc.-Grant.).2195 Wilson, Gustave Charles (Acc.-Grant.).2195 Wong, Sam (Acc.-Grant.).2196 CAISSES SAVINGS Caisse populaire de St-Eugène de d'épargne et de crédit and credit unions Granby (La) (Ext.terr.).2217 Caisse d'économie des employés de Bill Tioxide du Canada (Formation).2216 Sanctioned.2211 Sanctionnés.2211 2248 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100' année, n° lk COMPAGNIES COMPANIES Avis relatifs Notices relative à la loi des to the Act of Autorisées Licensed h faire des affaires to do Business Compagnie Foncière du Manitoba (1967) limitée (La).2196 MTB Corporation.2196 T.S.Simms & Co.Limited.2197 Chartes \u2014 Charters \u2014 Abandon de Surrender of Armitage South Shore Tire Co.Ltd.2211 Bastien incorporé.2211 Cité Automobile ltéc.2212 Cornell Realties Inc.2212 Crescent Management Corporation.2213 Daignault & Fils inc.2213 Gloria Gloves (Canada) Ltd.2213 Lachine Ladies Wear Inc.2212 Musique & Sports Itée.2214 Ray-Fort inc.2212 Ritz Supplies Inc.2212 Salon Épilatoire Louisctte inc.2212 Samson & Fils inc.2213 Sealine Development Ltd.2213 Smaliwood Markham Advertising Inc.2212 Tabah (Elie) Trading Ltd.2213 Divers Miscellaneous Association des entrepreneurs en travaux municipaux des Laurcntidcs inc.(Dir.) (Règl.-By-laws)._.2216 Amis des mouvements scout et guide de Cliarlcmagnc (Les) (Règl.-By-laws).2215 Association provinciale des constructeurs d'Habitations du Québec inc.(Règl.).2215 Boutiques Les Impeccables inc.(Dir.).2215 Club du Petit Lac Brompton (Règl.-By-laws).2216 Compagnie Générale de Placement Limitée (Dir.).2214 Corporation de gaz naturel du Québec (Dir.).2216 Fortier (Hermann) incorporée (Dir.).2214 General Investment Company Limited (Dir.).2214 Jeune Chambre d'Hébertvillc-Station (La) (Règl.-By-laws).2214 Ligue Electrique dc Québec (Correction).2215 Loranger & Frères Itée (Dist.Actif- Assets).2214 Nesbitt, Thomson and Company Limited (Dir.).2214 Nesbitt, Thomson and Company limitée (Dir.).2214 Queliec Electrical League (Correction) 2215 Quebec Natural Gas Corporation (Dir.).2216 Quebec Provincial Home Builders Association Inc.(By-laws).2215 Société des Travailleurs des Mines inc.(Règl.-By-laws).2214 Sunnybrook Swimming Pool Association (Dir.).2216 Sunnvbrook Swimming Pool Association (Règl.-By-laws).2215 Sièges sociaux Head Offices Chateau Corp.2197 Compagnie Générale dc Placement, limitée (La).2197 Dionne (J.R.) inc.2197 Domaine St.Augustin inc.2200 Fonderie Paccard Québec Itée (La).2200 General Investment Company, Limited.2197 Industrial Protective Services Inc.2200 Institut des Sciences Commerciales.2198 Le Mac Mobile Food Unit Ltd.2198 Lou Potrclcum Inc.2200 Mercury Maintenance & Painting Ltd.2199 Meunerie Mobile Le Mac Itée.2198 Milton-Ste.Famille Corporation.2198 Peinture & Décor (St.Jean) Itée.2199 Peinture & Entretien Mercury ltéc.2199 Petroleum (Lou) Inc.2200 Quemat Inc.2199 Re-Hec inc.2198 Rycade inc.2199 Salon Jade inc.2200 Vallée des Sables inc.2198 Lettres patentes Letters Patent Acadian Audio-Visual Systems Ltd.2128 Acton Vale transport inc.2128 Ada's Beauty Salon Inc.2129 Adnaco Company Inc.2129 Agences Esmar Itée.2129 American Meat Packers Inc.2130 Amusements Rayco ltéc.2173 Armenian Social and Recreation Club.2130 Assembly Theatre (The).2130 Association Athlétique Intcrcollégiable - Région dc Québec.2131 Association générale des Constructeurs (L').2151 Association professionnelle de l'Etat-Major du Service dc la Police de Laval inc.(L*).2131 Athletic Wear Inc.2186 Baldassarre Brothers Limited.2132 Bcauchesne Lumber lue.2132 Bcaudin Nobert inc.2132 Bejado inc.2132 Bercourt inc.2133 Bétons Asco inc.2133 Bifcoteck inc.(Le).2133 Bigio Trading Co.Ltd.2134 Boudrcault.(Philippe) ltéc.2134 Black Bottom Inc.2134 Bonbons du Chatel inc.2135 Boutique des Quatre Saisons Itée.2135 Boutique Lucerne (1968) Itée.2135 Builtec Homes Inc.2135 Capitol Steel Products Limited.2136 Cartes dc souhaits Exclusc inc.2136 Cascades Mountains Farming Ltd.2140 Caspo Rent-All Ltd.2136 Centre Laval Merchants Association.2137 Centre Psycho-pédagogique de Québec inc.2137 Centre sportif du 1er Rang inc.(Le)____ 2138 Cha-Lem inc.2138 Chaussures Porto - Fino inc.2138 Cheval de Bois ltéc (Le).2139 Chez Pierre & Carlo inc.2139 Club Connaissance du Monde inc.2139 Clem inc.2139 Club nautique de Sillerv.2140 Club sportif Cowansville inc.2140 Compagnie Adnaco inc.2129 Compagnie de placement Sauvcmont inc.2140 Compagnie des Attractions de Montréal Itée (La).2141 Constructions Grenoble inc.(Les).2141 Continental Air Freight Ltd.2141 Corporation S.O.M.(La).2176 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.U 2249 Lettres patente» Letters Patent (suite) (continued) ( 'osmétiques « Gai de Paris » inc.2142 Coupole des Gastronomes inc.(La)- 2142 DBM Industries Limited.2142 D'Armours (B.) construction ltéc.2143 Dawes (B.L.) Equipment Inc.2143 Dcsbiens (L.Paul) Itée.2143 Deko Design Ltd.2144 Dessin Deko Itée.2144 Développement Immobilier dc Sherbrooke inc.(Le).2144 I (éveloppcment du Lac Manon inc.2145 Donnan Cartage Inc.2145 Eagle Door Inc.2145 Elite Sportswear Ltd.2145 Entreprises Éclair inc.(Les).2146 Enterprises Galex Itée.2146 Entreprises Latines Américaines ltéc (Us).2161 Entreprises Lucien Brouillette, Itée.2146 Entreprises Mont Sub inc.2147 Équipements Grenier inc.(Les).2147 Esmar Agencies Ltd.2129 Espérance investissement inc.2147 Europe Plastic Moulds, Tools & Dies Ltd.2148 Exclusc (ireeting Cards Inc.2136 F.G.L.Holdings Inc.2148 F.P.Construction Inc.2148 Farbstein Factory Ltd.2165 Ferme La Poule Blanche.Itée.2149 Fermes Monts Cascades Itée.2149 Fiorito assurance limitée.2149 Fondation Populaire des bourses d'études inc.2150 Galaxv Productions Inc.2172 Galerie d'Art La Plaza inc.2150 ( ialeries Schertle inc.(Les).2150 Gauthier Mining Group Ltd.2151 General Builders Association.2151 (ireek Canadian National Brotherhood (The).2151 ( iroupe Minier Gauthier Itée (Le).2151 Habitations Futura inc.2152 I larold Standard and Associates Inc.2152 Hermitage Club (The).2152 Hotel Holdings Corp.2153 Hôtel-Motel Crystal inc.2153 Hotel Val d'Or inc.2153 Ice Cream Inn Ltd.2154 Immeubles Deux Montagnes inc.2154 Immeubles Lussier Itée.2154 Industries DBM limitée (Us).2142 Ingrid's Inner Circle Inc.2155 Institut d'Orientation des Métiers du Quél>cc inc.2155 Institut Francc-Laure inc.2155 Intcgron Associates Incorporated.2156 Intercity Food Services Inc.2156 Investissements Perron inc.2157 Irene Holdings Inc.2157 J.M.Autos limitée.2157 J.& W.Investments Inc.2158 Jacobi's Inc.2158 Jardins St-Hubert Inc.2158 Jet Uranium Limited.2159 Jeune Chambre de Gagnon inc.(La).2159 Julian Investment Corporation.2159 Knowlton construction inc.2159 Knox Holdings Limited.2160 Kovet Shopper's Discount Ltd.2160 L.G.Electric Appliance Inc.2160 Lapointe.Associés inc.2161 Latin American Enterprises Ltd.2161 Leader Trading Ltd.2161 Letournair inc.2162 Ligue des Propriétaires de Montréal-Nord inc.(La).2162 Librairie Classique de Hull ltéc.2163 Loisirs Sac Spécialité inc.2163 Longhorn Marketing & Franchising Corp.2163 Lonmont Inc.2164 Lucerne Dress (1968) Inc.2164 Lyons Discount Corp.2164 M & R Holdings Ltd.2164 Mail-Mart Inc.2165 Maison Rita inc.2165 Manufacture Farbstein Itée.2165 Maranda équipement inc.2166 Marché Bardy inc.2166 Martin (Julien) & fils Itée.2166 McMarjo Manufacturers Limited.2167 Mine Manufacturing Co.Ltd.2167 Miroirs Directionnels inc.(Les).2167 Mode Féminine inc.2168 Montreal Crane Rentals Company Limited.2168 Mont Sub Enterprises Inc.2147 Morav Holding Corp.2168 Napierville (îrowers Inc.2168 Ncuvico liée.2169 Ordre Martinistc et Synarchique du Québec.2169 P & G Amusements Inc.2170 Pavillons Bois-Joly inc.(Les).2170 Peinture & Décor (St Jean) Itée.2170 Pelletier Acoustic Inc.2170 Pelletier acoustique inc.2170 Placements G.M.inc.(Les).2171 Placements Lomat inc.(Les).2171 Placements Morin-Lapointe inc.2172 Porto \u2014 Fino shoes Inc.2138 Productions Galaxie inc.2172 Produits inoxydables Bidcau Itée (Les).2175 Produits Tur - Mo inc.(Les).2172 Quebec Trade Orientation Institute Inc.2155 Queen Mary Boad Valet Service Inc\u2014 2173 Ralco Corporation.2173 Rayco Amusements Ltd.2173 Regent Construction (1968) Ltd.2174 Reliable Button & Buckle Corp.2174 Restaurant Apolco inc.2174 Rex Auto Sales Inc.2174 Rideau Stainless Products Ltd.(Les).2175 Road Air Services Ltd.2175 Roy, Tétreault inc.2175 S.O.M.Corporation.2176 Saint-Onge électronique inc.2176 Salaison Américaine inc.2130 Salaison Turcot inc.2176 Salon La Comtesse inc.2177 See Europe Tours Inc.2177 Sherbrooke Dry Wall Inc.2177 Sherbrooke Provisions Inc.2178 Sherbrooke Restaurant Inc.2178 Sicotte Itée.2178 Sillery Nautical Club.2140 Simaplast limitée.2179 Société de l'Édifice Place Notre-Dame inc.2179 Socon Inc.2179 Somorsct Development Ltd.2179 Spartacus Realties Inc.2180 Speyer Agencies Inc.2180 Sportsmen Club Cowansville Inc.2140 Sportmaster Inc.2180 Stark Industries Ltd.2181 Studio LeBel inc.2181 Système de location commerciale (SLC) inc.2181 2250 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, 100' année, n° U Lettres patentes Letters Patent (suite) (continued) T.- P.Enterprises Ltd.2182 Tabagie du (.'entre inc.2182 Tamarak Construction Inc.2182 Tatra Travel Inc.2187 Taxi Meter Sales & Service Inc.2183 Tcchron Medical Inc.2183 Thor-Bec Corp.2183 Tiki Originals Inc.2184 Tracomin (Imporl-Export) Inc.2184 Tatral Travel Inc.2187 Traub (William).2184 Trudel & frères inc.2185 Two Mountains Realties Inc.2154 United Carpet Co.Ltd.2185 United Optical (1968) Inc.'.2185 Vêtement athlétique inc.2186 Villa Stc-Marcelline.2186 Vittorio Restaurant & Pizzeria Inc.2186 Voyages Tatra inc.2187 Voyages Voir l'Europe inc.(Les).2177 Vulcain Alarme & Incendie inc.2187 Welch (Judy) Schools (Quebec) Limited 2187 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Abattoir Gérard inc.2188 Amyot Automobiles Itée.- 2188 Associated Answering Services Limited.2188 Association des Guides Universitaires de Montreal inc.(L').2188 Beauward Ltd.218S Chaussures Karol inc.2189 Chaussures Studio 10 Itée.2193 Croteau (B.) Assurances Itée.2189 Gimiro inc.2189 Hôpital Notre-Dame duLac (Correction).2193 Industries Rojean ltéc (Les).2189 Institut Stafford inc.2190 Karol Shoes Inc.2189 Lamothc (D.) Ltd.2190 Marcoux (Roland) limitée.2190 Molybdenite Corporation of Canada Limited.2190 Montréal Dauphine inc.2191 Montreal Hardware Manufacturing Company Ltd.2193 Pease Investments Limited.2191 Planned Investments Corporation.2191 Programmes d'Investissements Capitalisés, ltéc.2191 Renault (P.F.) limitée.2191 Rojean Industries Ltd.2189 Safety Glove and Clothing Inc.2191 Simtel Incorporated.2192 Simtel incorporée.2192 Société Chimique Valco Itée (La).2192 Société Lancel inc.(La).2192 Société Manufacturière de Quincaillerie Montréal ltéc (La).2193 Stafford Institute Inc.2190 Studio 10 Shoes Ltd.2193 Tcxtilco inc.2193 DEMANDES APPLICATIONS à la Législature to Legislature Abbaye dc Saint-Romuald des Moniales cisterciennes de la Stricte Observance 2204 Abbey of Saint-Romuald of the Moniales cistercienm s de la Stricte Observance 2204 Anjou, ville - town et al.2202 Association des Évaluatcurs Indépendants du Québec.2202 Clarke, munie.2203 County Club of Montreal.2201 Dubcrger, ville - town.2203 Fabrique de la paroisse de Ste-Margue- ritc dc Blairfindie (La).2205 Lachinc, cité - city.2204 Lebel-sur-Quévillon, ville - town.2202 Lucerne, munie.2203 Salaberry-de-Valleyficld, cité - city.2201 St-Charles dc Lachenaie, par.2204 Szcle, Etienne.2203 MINISTÈRES DEPARTMENTAL Affaires municipales Municipal Affairs Belcourt, munie.2217 Éducation Education Municipalité scolaire de: School Municipality of: Dundee, (Dem.- Appl.).221S Pinchurst and East Greenfield (Prot.) (Dcm.-Appl.).2218 Stanstcad County (Prot.) (Erratum) .2218 Finances Finance Assurances: Insurance: Beacon Insurance Company Limited (Annul perm.).2217 Compagnie d'Assurance Mutuelle contre le Peu de la municipalité du village dc St-Gérard, comté dc Wolfe (Annul, perm.).2218 PROCLAMATION PROCLAMA TION Arbor Week.2221 Semaine dc l'arbre.2221 RÉGIE QUEBEC des marchés agricoles Agricultural du Québec Marketing Board Producteurs dc bois dc pulpe, Sagucnay (Mod.au plan conjoint).2219 Pulpwood Producers, Sagucnay (Amend.to a point plan).2219 SOUMISSIONS TENDERS Anjou, ville-town.2226 Candiac.ville-town.2223 St-Calixtc, munie.2222 Shawinigan.cité-cily.222S Vol d Or, ville-town.2230 Verdun, c.s.c.-c.s.c.2225 SYNDICATS SYNDICATES Professionnels Professional Association des camionneurs artisans du comté de Chauvcau (Const.-1ne).2220 Association des diplômes en pharmacie (L') (Const.).2221 Association des employés dc Scott La Salle (Nom-Name ch.).2220 Association of Graduates in Pharmacy (The) (/ne.).2221 Syndicat des Cadres de l'Université de Montréal (Le) (Const-Inc.).2220 VENTES Effets non-réclamés SALES Unclaimed Goods Canadian Pacific Express Company.2231 Messageries Canadien Pacifique.2231 GAZETTE OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.100, No.U 2251 SHERIFS SHERIFFS Drummond Drummond Caisse populaire de St-Germain dc ( i runtham (La) vs Deschambault et al.2234 Hauterive Hauterive Brouillard (C.A.) ltéc vs Bouchard.2235 Sept-Iles, c.s.-s.c.vs Les Immeubles Iles Itée.2235 Hull Hull ( 'barter Credit Corp.rs Lynch.2236 Gavard Matériaux Construction ltéc H Hcirs-Héritiers Gaston Lachapcllc.2236 Niagara Mortgage & Loan vs Andrasi.2236 Iberville Iberville GrothrsDcekc .2237 Joliette Joliette < ipera Diamond limitée rs Marchand.2237 kamouraska Kamouraska Bérubé m Larrivée.2238 Montréal Montreal Beauregard r* Chartrand.2240 Canada Trust Company (The) r* Wilson etal.2239 Cliait, Aronovitch et al vs Du Lac Development Inc.2240 Income Tax Act, and Amendments (The) vs Séante.2241 Loi de l'impôt sur le revenu r* Szante.2241 Placements Port-Royal inc.(Les) vs El-bay Construction inc.2239 Royal Trust Company (The) vs Boivin etal.2240 Yolles et al vs Mace Development Ltd.2241 Rimouski Rimouski Chinic inc.vs Landry.2245 Vaillancourt M Gagnon.2245 Saint-François Saint Francis Rock Island, ville-town m Nirdac Inc.2246 Taxes Taxes Chicoutimi, cité - city.2231 Shawiuigan, cité-city.2233 "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.