Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 20 décembre 1969, samedi 20 (no 51)
[" 101» année vol.101 i 3UEBEC -1UEBEC N« 51 7015 hiette officielle à Québec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE Québec, samedi 20 décembre 1969 Règlements 1° Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.0° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7° La Goutte officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec, a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.S0 Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9 Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et u autre des frais onéreux de reprise.Québec, Saturday, December 20, 1969 Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gazette is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, The Québec Official Publisher, reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Quibec, ROCH LEFEBVRE, Québec Official Publiiher 7016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 décembre 1969, 101' année, n° 61 Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 35 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 15 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $4 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement: du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, 815 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Rocii Lefebvre.Hôtel du Gouvernement, Québec, 30 avril 1969 Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 35 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 15 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $4 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods: From January 1st to December 31st, $20; April 1st to December 31st, $15 and July 1st to December 31st, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazelle carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Rocn Lefebvre, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, April 30, 1969 27440 \u2014 l-52-o Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis No 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107).Lettres patentes Action-Cranby inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Ix>i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-H.Masscy, avocat, 338, rue Begin, Doris Bolger, secrétaire, fille majeure, 261, rue Frechette, et Côme Poulin, stagiaire en droit, 15, rue (ïuy, tous trois de Granby, pour les objets suivants: Promouvoir l'essor économique, industriel et social de la ville de Granby, sous le nom de « Action-Granby inc.»._Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $100,000.Le siège social de la corporation est à Granby, district judiciaire de Bedford.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-PllIUPI'e Uouciiard.32290-o 5070-69 Ambassador Jewellery Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8c jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Salomon Benmcrgui, marchand, 4823, avenue Kent, Rahma Azerraf, ménagère, veuve de Salomon Azerraf, 4025, Edouard-Montpetit, app.5, tous deux de Mont- Letters Patent Action-Granby inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Jean-H.Massey, advocate, 338 Begin Street.Doris Bolger, secretary, spinster of the full age of majority, 261 Frechette Street, and Conic Poulin, articled law student, 15 Guy Street, all three of Granby, for the following purposes: To promote the economical, industrial and social advancement of the city of Granby, under the name of \"Action-Granby inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $100,000.The head office of the corporation is at Granby, judicial district of Bedford.Ls-Phiuppf.Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 \u2022 5070-iH' Ambassador Jewellery Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date lli«' 8th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Salomon Benmergui, merchant, 4823 Kent Avenue, Rahma Azerraf, housewife, widow of Salomon Azerraf, 4025 Êdouard-Montpelit.Apt.5, both of Montreal, and Esther Benmergui. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1969, Vol.101, No.61 7017 real, et Esther Benmergui, ménagère, épouse divorcee de Rudolph Spungin, 104, avenue Oak-wood, West Hartford, Connecticut, E.U.A.iioiii les objets suivants: La fabrication et le commerce de bijoux, montres, joyaux et articles et marchandise de toutes sortes et de toute description, sous le nom de « Ambassador Jewellery Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 201) actions privilégiées d'une valeur au pair de Son chacune.Le siège social de la compagnie est 1604 ouest, rue Sainte-Catherine, Montréal, district judiciaire île Montréal.I.e mus-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32200 4876-69 housewife, wife divorced of Rudolph Spungin, 104 Oakwood Avenue, West Hartford, Connecticut, U.S.A., for the following purposes: To manufacture and deal in jewellery, watches, gems and wares and merchandise of all kinds and description, under the name of \"Ambassador Jewellery Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of a par value of $10 each and 200 preferred shares of a par value of $50 each.The head office of the company is at 1604 St.Catherine Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 4876-69 Les Ameublements Mailhot & Dussault inc.Les Ameublements Mailhot & Dussault inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gaétan Mailhot, entrepreneur, Claude Dussault, superviseur, et Nicole Hémond, secrétaire, épouse de Laurent Coté, tous trois de Princeville, pour les objets suivants: Faire le commerce de meubles et accessoires électriques, sous le nom de « Les Ameublements Mailhot & Dussault inc.», avec un capital total de S-10,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de SU) chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Princeville, district judiciaire d'Arthabaska.h sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-e 5130-69 B.C.D.Aluminium Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jean-Marc Champagne.6545, Bordeaux, Gilles Bellemare, 4325, Bélanger, app.4, tous deux de Montréal, et André Desrochers, 7579, Valdombre, Saint-Léonard, tous trois vendeurs, pour les objets suivants: l'aire le commerce de marchandise et articles fabriques totalement ou en partie de métaux ou bois, sous le nom de < B.C.D.Aluminium Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 8042, rue St-lliibert, Montréal, district judiciaire de Montréal./.(\u2022 sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32200-o 3554.69 I\".H.Bélanger & Associates Co.Ltd.I*.R.Bélanger & associés Cie ltéc Avis est donné qu'en vertu de la première partic de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gilles Chiquette, 849, Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gaétan Mailhot, contractor, Claude Dussault, superviser, and Nicole Hémond, secretary, wife of Laurent Côté, all three of Princeville, for the following purposes: To deal in furniture and electrical appliances, under the name of \"Les Ameublements Mailhot & Dussault inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Princeville, judicial district of Arthabaska.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5130-69 B.C.D.Aluminium Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of October, 1969, have been issued by the Lieuienant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Marc Champagne, 6545 Bordeaux, Gilles Bellemare, 4325 Bélanger, Apt.4, both of Montreal, and André Desrochers, 7579 Valdombre, Saint-Léonard, all three salesmen, for the following purposes: To deal in merchandise and articles manufactured totally or partially in wood or metal, under the name of \"B.C.D.Aluminium Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 8042 St-Hubert Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial histitutions, Companies and Cooperatives.32290 3554-69 P.R.Bélanger & Associates Co.Ltd.P.R.Bélanger & associés Cie ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Chiquette, 849 Honneur, Lon- 7018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 décembre 1969, 101' année, n° 51 Honneur, Longueuil, René Talbot, 799, Houde, Saint-Lambert, tous deux avocats, et Paul-Roger Bélanger, ingénieur, 2160, LePailleur, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction, de placement et de portefeuille, sous le nom de « P.R.Bélanger & Associates Co.Ltd.\u2014 P.R.Bélanger & associés Cie ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 310 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 2160, rue LePailleur, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institut ions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 4671-69 F.Bujold inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Fcrnand Bujold, agent manufacturier, Julia Arbour, ménagère, épouse dudit Fcrnand Bujold, tous deux de 185, rue Belzile, Rimouski, et Jean-Marie Bujold, comptable agréé, New-Richmond, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents manufacturiers, sous le nom de « F.Bujold inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 185, rue Belzile, Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Le sons-ministre des institut ions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 4524-69 Candie Shac Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Ross Goodwin, avocat, 156, Grande-Allée ouest, Hélène Delisle, 370, Des Franciscains, et Dcnysc Cloutier, 120, rue Fraser, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, tous trois de Québec, pour les objets suivants: Exploiter des magasins et ateliers et faire le commerce de bougies et accessoires de toutes sortes, sous le nom de « Candie Shac Inc.», avec un capital total de $500, divisé en 100 actions ordinaires de $5 chacune.Le siège social de la compagnie est 2700, boulevard Laurier, Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 5145-69 Caprina Knitwear Mfg.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de septembre 1969, constituant en corporation: Joseph Mendelson, 5622, avenue Jellicoe, Côte Saint-Luc, Martin Gross, 1105, Ridgewood Drive, Laval, et Harold Dizgun, 1000, avenue Pratt, Outremont, tous trois avocats, pour les objets suivants: gueuil, René Talbot, 799 Houde, Saint-Lamberl, both advocates, and Paul-Roger Bélanger, engineer, 2160 LePailleur, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a real estate, constriction, investment and holding company, under the name of \"P.R.Bélanger & Associates Co.Ltd.\u2014 P.R.Bélanger & associés Cie ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 2160 LePailleur St., Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, DeptUy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 4671-09 F.Bujold inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Fernand Bujold, manufacturer's agent, Julia Arbour, housewife, wife of the said Fernand Bujold, both of 185 Bclzile Street, Rimouski.and Jean-Marie Bujold, chartered accountant, New-Richmond, for the following purposes: To carry on businesses manufacturer's agents, under the name of \"F.Bujold inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at 185 Belzile Street, Rimouski, judicial district of Rimouski.Ls-Philippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 4521-09 Candle Shac Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of October, 1969, have been issued by the Lieuscnant-Governor of the Province, incorporating: Ross Goodwin, advocate, 156 Grande-Allée West, Hélène Delisle, 370 Des Franciscains, and Denyse Clouticr, 120 Fraser Street, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, all three of Québec, for the following purposes: To oi>erate stores and workshops and to deal in candles and accessories of all kinds, untler the name of \"Candle Shac Inc.\", with a total capital stock of $500, divided into 100 common shares of $5 each.The head office of the company is at 2700 Laurier Boulevard, St.Foy, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5145-69 Caprina Knitwear Mfg.Ltd.Notice is given that under Part I of I lie Companies Act, letters patent, bearing tinte the 22nd day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Joseph Mendelson, 5622 Jellicoe Avenue, Côte Saint-Luc, Martin Gross, 110) Ridgewood Drive, Laval, and Harold Dizgun.1000 Pratt Avenue, Outremont, all three advocates, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1969, Vol.101, No.61 7019 La confection et le commerce de tricots de toutes sortes et de toute description et d'accessoires de toutes sortes, sous le nom de « Caprina Knitwear Mfg.Ltd.», avec un capital total de 140,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 cliuciinc et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1385, rue Ma/.iircttc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-l'lIlLII'l'k Bouchard.32200 4539-69 To manufacture and deal in knitted goods of every kind or description and all accessories, under the name of \"Caprina Knitwear Mfg.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1385 Mazurette Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Phimppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 4539-69 Cerbère Films Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le I i eu tenant-gouverneur «le la province a accorde des lettres patentes, en date du 15e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Adricn-R.Paquctte, 212, Hloomficld, Outremont, Louis-A.Toupin, 3455, McCarthy, Saint-Laurent, tous deux avocats, et Micheline Villeneuve, secrétaire, épouse de Jean-Pierre Lamoureux, 2265, Sauriol est, .Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des studios pour la production cinématographique et faire la production de films, sous le nom de * Cerbère Films Inc.», avec un capital total de $250,000, divisé en 50,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 400 actions privilégiées de $500 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal, /.r snus-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppk Bouciiahd.32290-o 4943-69 Cerbère Films Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, l>earing date the 15th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Adrien-R.Pnqucttc, 212 Bloomficld, Outrcmont, Louis-A.Toupin, 3455 McCarthy, Saint-Laurent, both advocates, and Micheline Villeneuve, secretary, wife of Jean-Pierre Lamoureux, 2265 Sauriol East, Montreal, for the following purposes: To operate cinematographic production studios and to act as films producers, under the name of \"Cerbère Films Inc.\", with a total capital stock of $250,000, divided into 50,000 common shares of $1 each and 400 preferred shares of $500 euch.The bead office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Lb-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.32290 4943-69 Chez Terzi Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de septembre 1969, constituant en corporation: Max S.Kaufman, 574.avenue Claremont, YVestmount, Oscar Respite, 4945, Glcncairn, Montréal, et Sydney B.Sederoff, 80, avenue Crestwood, Montréal-Ouest, ton-, trois avocats, pour les objets suivants: Tenir restaurants, hôtel, auberges, tavernes, buffets et maisons de chambres, sous le nom de «('lie/.Terzi Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 15,000 actions ordinaires de $1 chacune et 2,500 actions privilégiées de $10 charnue.Le siège social de la compagnie est à Piedmont, district judiciaire de Terrebonne.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290 4332-69 Chez Tcrzi Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th (lay of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor-]>orating: Max S.Kaufman, 574 Claremont Avenue, Wcstmount, Oscar Respitz, 4945 Glencairn, Montreal, and Sydney B.Scderoff, 80 Crestwood Avenue, Montreal West, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as restauiateurs, hotel, inn, tavern, refreshment room and lodging housekeepers, under the name of \"Chez Terzi Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 15,000 common shares of SI each and 2,500 preferred shares of $10 each.The bead office of the company is at Piedmont, judicial district of Terrebonne.Lb-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 4332-69 Circca inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Roger Énault, 944, jir'ggs, Léo Gauthier, 100, Benoit est, et Jacques I.cniaire, 2026, boulevard Therrien, tous trois vendeurs, de Longueuil, pour les objets suivants: l'aire le commerce de produits et articles devant servir à la coiffure ou au traitement de la peau, sotis le nom de « Circca inc.», avec un capital Circca inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roger Énault, 944 Briggs, Léo Gautiiier, 100 Benoit cast, and Jacques Lemaire, 2026 Therricn Blvd., all three salesmen, of Longueuil, for the following purposes: To deal in products and articles used in hair-dressing or in skin treatment, under the name of \"Cireca inc.\", with a total capital stock of 7020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SO décembre 1969, 101' année, n° 61 total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 43, rue Amos, Place Bonaventure, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 5045-69 Le Club Auto-neige de Princeville inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Paul-R.Lacoursière, voyageur, Thérèse Jacques, ménagère, épouse dudit Paul-R.Lacoursière, et Adélard Lachapelle, mécanicien, tous trois de Princeville, pour les objets suivants: Former et exploiter un club sportif et promouvoir en particulier le sport de la moto-neige, sous le nom de * Le Club Auto-neige de Princeville inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $20,000.Le siège social de la corporation est à Princeville, district judiciaire d'Arthabaska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Ls-Philippe Bouchard, 32290-o 5131-69 Club Auto-Neige St-Narcisse inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour de septembre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Sylva Lefebvre, commis des postes, 120, Renaud, Jean-Pierre Hamel, publiciste, 116, Renaud, tous deux de Québec, Real Begin, mécanicien, 3185, Place des Rossignols, Orsainville, Jacques Gagné, vendeur.Normand Toutant, gérant, Michel Garon, Léo Baron, tous deux camionneurs, François Boucher, et Conrad Bacon, ces deux derniers mécaniciens, ces six derniers de Saint-Narcisse-de-Beaurivagc, pour les objets suivants: Promouvoir le sport de l'auto-neige, sous le nom de «Club Auto-Neige St-Narcisse inc.».Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $1,200.Le siège social de la corporation est à Saint-Narcisse-de-Beaurivagc, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 4441-69 Club-Colombo Lachinc incorporée Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Arthur Plante, directeur, 3815, Victoria, Guy Bellanger, métallurgiste, 672,17e Avenue, Gérard Lacoste, maître-coiffeur, 616, 12e Avenue, Léo Sauvé, rentier, 1710, Remembrance, et Julien Comcau, marchand, 813, 55e Avenue, tous cinq de Lachinc, pour les objets suivants: $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 43 Amos St., Place Bonaventure, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5045-69 Le Club Auto-ncigc de Princeville inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, to incorporate a corporation without share capital: Paul-R.Lacoursière, traveller, Thérèse Jacques, housewife, wife of the said Paul-R, Lacoursière, and Adélard Lachapelje, mechanic, all three of Princeville, for the following purposes: To form and operate a sports club, and to promote the sport of snow-mobiling in particular, under the name of \"Le Club Auto-neige de Princeville inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $20,000.The head office of the corporation is at Princeville, judicial district of Arthabaska.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5131-69 Club Auto-Neige St-Narcissc inc.Notice is given that untler Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Sylva Lefebvre, postal clerk, 120 Renaud, Jean-Pierre Hamel, publicist, 116 Renaud, both of Québec, Real Begin, mechanic, 3185 Place des Rossignols, Orsainville, Jacques Gagné, salesman.Normand Toutant, manager, Michel Garon, Léon Baron, both truck drivers, François Boucher, and Conrad Bacon, the latter two mechanics, the latter six of Saint-Narcisse-de-Heauri-vage, for the following purposes: To promote snowmobiling, untler the naine of \"Club Auto-Neige St-Narcisse inc.\".The amount to which is limited the annual revenue on immovables which may be held and owned by the corporation is of $1,200.The head office of the corporation is at Sainl-Narcisse-dc-Beaurivagc, judicial district of Quebec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 4441-w Club-Colombo Lachinc incorporée Notice is given that under Part HI of the.Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Arthur Plante, director, 3815 Victoria, Guy Bellanger, metallurgist, 672, 17th Avenue, Gérard Lacoste, hairdresser, 616, 12th Avenue.Léo Sauvé, annuitant, 1710 Remembrance, ami Julien Comeau, merchant, 813, 55th Avenue, all five of Lachine, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1969, Vol.101, No.61 7021 L'organisation des loisirs, sous le nom de « Club-Colombo Lachinc incorporée ».I.o montant auquel est limitée la valeur des liions immobiliers que peut acquérir et posséder In cor|>oration, est de $200,000.Le siège social de la corporation est à Lachinc, district judiciaire de Montréal./,(\u2022 sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIILIPPE bouchard.32290-O 4233-69 Club d'Arl-Gil inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Bihianc Brun, ménagère, épouse de Robert Lamb, 73.10e Rue, Bourlamaquc, Edith Lesagc, ménagère, épouse de Denis Drouin, 867, 5e Rue, et Simone Cardinal, ménagère, épouse de Gérard N'adeau, 1022, 6c Rue, ces deux dernières de Val d'Or, pour les objets suivants: Promouvoir l'étude et la pratique des arts plastiques et notamment la céramique, la poterie et les arts scripturaircs, sous le nom de « Club d'Art-Gil inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la \u2022¦nrpiiration, est de $50,000.Le siège social de la corporation est à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Ac sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlHLlPPE bouciiahd.32290-O 5071-69 Club de Courses Gcntilly inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gilles Blanchctte, Kmile Poisson, Guy Piché, O.-Émile Carigunn, tous qunlrc cultivateurs, Sylvain Laroche, commerçant, Marcel Founder, comptable, Jacques Manchette, industriel, Jean Villeneuve, notaire, Fcrnand Carignan, garagiste, et Jacques Cari-gnan.boucher, tous de Bécancour, pour les objets suivants: Exploiter une piste de courses, sous le nom de « ' lub de Courses Gcntilly inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 30,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 400 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compagnie est à Bécancour, district judiciaire de N'icolet.Le mus-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchaud.32290-o 5019-69 La Cie d'expansion de Lachenaie inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutcnant-gonvenieur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Philip Shugar, avocat, (1267, Macdonald.Montréal, Carole Neal, épouse de James Neal, 271, McLeod, Chatcau-guay, et Vera Burt, fille majeure, 3466, Aylmcr, \"Pp.307, Montréal, ces deux dernières secrétaires.|>our les objets suivants: The organization of spare-time activities, under the name of \"Club-Colombo Lachinc incorporée\".To amount to which is limited the value of the immovables which the corporation may hold and own is of $200,000.The head office of the corporation is at Lachinc, judicial district of Montreal.Lb-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 4233-69 Club d'Art-Gil inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Bibianc Brun, housewife, wife of Robert Lamb, 73, 10th St., Bourlamaquc, Edith Lcsage, housewife, wife of Denis Drouin 867, 5th St., and Simone Cardinal, housewife, wife of Gérard Nadeau, 1022, 6th St., the latter two of Val d'Or, for the following purposes: To promote the study and practise of the plastic arts and notably of ceramics, pottery and the scriptural arts, under the name of \"Club d'Art-Gil inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation is at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5071-69 Club dc Courses Gcntilly inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Blanchctte, Emile Poisson, Guy Piché, O.-Émile Carignan, all four farmers, Sylvain Laroche, trader, Marcel Founder, accountant, Jacques Blanchctte, industrialist, Jean Villeneuve, notary, Fernand Carignan, garage keeper, and Jacques Carignan, butcher, all of Bécancour, for the following purposes: To operate a race track, under the name of \"Club dc Courses Gentilly inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 30,000 common shares of $1 each and into 400 preferred shares of $25 each.The head office of the company is at Bécancour, judicial district of Nicolet.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5019-69 La Cic d'expansion de Lachenaie inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of Octol)er, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Philip Shugar, advocate, 6267 Macdonald, Montreal, Carole Neal, wife of James Neal, 271 McLeod ChAtcauguay, and Vera Burt, spinster of the full age of majority, 3466 Aylmcr, Apt.307, Montreal, the latter two secretaries, for the following purposes: 7022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 décembre 1969, 101' année, n° 51 Agir généralement comme agents et courtiers d'immeubles, évaluateurs de biens meubles et immeubles, sous le nom de « La Cie d'expansion dc Lachenaie inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 5029-69 Club Moto-Neige (La Tuque) inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: René Hamel, commis, 452, St-Benoit, Gabricl-E.Bcaulieu, employé dc C.I.P., 63, Laflèclic, et Paul Aubut, facteur, 519, Bostonnais, tous trois de La Tuque, pour les objets suivants: Promouvoir le sport de la moto-neige, sous le nom de « Club Moto-Neige (La Tuque) inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $50,000.Le siège social dc la corporation est 519, rue Bostonnais, La Tuque, district judiciaire dc Saint-Maurice.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 4840-09 Club Optimiste de Stc-Martinc inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Gilles Beaudin, agent dc circulation, 125, rue St-Josepb, Claude Chevrefils, assistant-surintendant, 348, rue St-Joscph, Jean-Pierre Brien, pres-sicr, 2b, rue Débattclher, Robert Goycttc, administrateur, 60, rue Touchettc, Lucien Pcrreault, professeur, 27, rue St-I^uis, Gilles Dubuc, propriétaire dc théâtre, 18, rue Desrochers, René Deschênes, surintendant, 26, Place Allard, Roger Gagnier, restaurateur, 335, rue St-Joscph, tous dc Sainte-Martine, et Jean-Paul Yelle, manufacturier, Saint-Urbain-Premier, pour les objets suivants: Établir et exploiter un club social, sous le nom de « Club Optimiste dc Stc-Martinc inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $50,000.Le siège social de la corporation est à Sainte-Martine, district judiciaire de Beauharnois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 5197-69 Club sportif Mont-Clair inc.Avis est donné qu'en vertu dc la troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: To act, generally, as real estate agents and brokers, movable and immovable property appraisers, under the name of \"La Cic d'expansion de Lachenaie inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5029-09 Club Moto-Ncigc (La Tuque) inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital : René Hamel, clerk, 452 Saint-Benoit Gabriel-K.Beaulieu, CLP.employee, 63 Laflèclic, and Paul Aubut, mailman, 519 Bostonnais, all three of La Tuque, for the following purposes: To promote snowmobiling, under the name of \"Club Moto-Ncigc (La Tuque) inc.\".The amount to which is limited the value of immovables which may be held and owned by the corporation is of $50,000.The head office of the corporation is at 519 Bostonnais Street, La Tuque, judicial district of Saint-Maurice.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 4840-69 Club Optimiste dc Stc-Martinc inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Gilles Beaudin, traffic constable, 125 Saint-Joseph Street, Claude Chevrefils, assistant superintendent, 348 Saint-Joseph Street, Jean-Pierre Brien.pressman, 2b Débattcllicr Street, Robert Goycttc, administrator, 60 Touchettc Street, Lucien Pcrreault, teacher, 27 Saint-Louis Street, (idles Dubuc, theatre proprietor, 18 Desrochers Street.René Deschênes, superintendent, 26 Place Allard.Roger Gagnier, restaurant owner, 335 Saint -Joseph Street, all of Sainte-Martine, and Jean-Paul Yelle, manufacturer, Saint-Urbain-Premier.for the following purposes: To organize and operate a social club, under the name of \"Club Optimiste de Ste-Martinc inc.\".The amount to which are limited the immovables which the corporation may holtl and own is of $50,000.The head office of the corporation is at Sainte-Martine, judicial district of Beauharnois.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5197-09 Club sportif Mont-Clair inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province t» incorporate a corporation without share capital: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December SO, I960, Vol.101, No.61 7023 Denis Benoit, garde-chasse, 293, St-Aimé, Yvon Lcfebvre, entrepreneur-plâtrier, tous deux de Louiseville, Maurice Therrien, scieur, Saint-Edmond, André Lefebvre, acheteur, 4610, St-Amlré, Saint-Léonard, Maurice Bellemare, opérateur, 571, Stc-Anne, Yaraachiche, Jean-Paul Boisvcrt, courtier d'assurance, 125, Pied de la Côte, Maskinongé, Hubert Clément, camionneur, 33.York, Saint-Barthélemy, et Lorenzo Marchand, cultivateur, Saint-Justin, pour les objets suivants: Organiser et développer un club de loisirs et sports, sous le nom de « Club sportif Mont-Clair inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de 850,000.Le siège social de la corporation est à Saint-Edmond, comté de Berthier, district judiciaire de .lolictte.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.322'JO-o 4517-69 Commission des Loisirs dc Deschênes Avis est donné qu'en vertu dc la troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: (iilles Dupont, secrétaire-trésorier, Deschênes, Yvau Couture, notaire, Touraine, et Jérôme-P.Somers, avocat, Lucerne, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de » Commission des Loisirs dc Deschêncs».I.e montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $10,000.Le siège social de la corporation est à Deschê-nes, district judiciaire de Hull.Le smts-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32200-0 4322-69 Comptoir Avicole Ormstown limitée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Paul Boldizar, aviculteur, Maria Vajda, ménagère, épouse dudit PaUl Boldizar, tous deux dc route rurale 3, Ormstown, et Bcla Kertcsz, comptable agréé, 4SSI, Isabelle, Montréal, pour les objets suivants: l'aire le commerce de tous produits avicoles et leurs sous-produits, sous le nom de « Comptoir Avicole Ormstown limitée », avec un capital total «le 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de SU) chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est route rurale 3.Ormstown, district judiciaire de Beauharnois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.\u2022i-200-o 3765-69 Confection J.E.Caron ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres Denis Benoit, game warden, 293 Saint-Aimé, Yvon Lefebvre, plaster contractor, both of Louiseville, Maurice Therrien, sawyer, Saint-Edmond, André Lcfebvre, purchaser, 4610 Saint-André, Saint-Léonard, Maurice Bellemare, operator, 571 Sainte-Anne, Yamachiche, Jean-Paul Boisvert, insurance broker, 125 Pied de la Côte, Maskinongé, Hubert Clément, truck driver, 33 York, Saint-Barthélemy, and Lorenzo Marchand, farmer, Saint-Justin, for the following purposes: To organize and promote a recreational and sports club, under the name of \"Club sportif Mont-Clair inc.\".The amount to which are limited the immovables which may be held and owned by the corporation is of $50,000.The head office of the corporation is at Saint-Edmond, county of Berthier, judicial district of Joliette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 4517-69 Commission des Loisirs de Deschênes Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Gilles Dupont, secretary-treasurer, Deschênes, Yvan Couture, notary, Touraine, and Jérôme-F.Somcrs, advocate, Lucerne, for the following purposes: The organization of spare time activities, under the name of \"Commission des Loisirs de Deschênes\".The amount to which are limited the immovables which may be held and ownc«l by the corporation is of $10,000.The head office of the corporation is at Deschênes, judicial district of Hull.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 4322-69 Comptoir Avicole Ormstown limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul Boldizar, breeder of fowls, Maria Vajda, housewife, wife of the said Paul Boldizar, both of rural route number 3, Ormstown, and Bela Kertesz, chartered accountant, 4881 Isabelle, Montreal, for the following purposes: To deal in all avicultural products and their by-products, under the name of \"Comptoir Avicole Ormstown limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at rural route 3, Ormstown, judicial district of Beauharnois.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 3765-69 Confection J.E.Caron ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of October, 1969, have been issued by 7024 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 décembre 1009, 101' année, n' 51 patentes, en date du 21c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: J.-Eudore Caron, industriel, Louis-Marie Caron, assistant de la production, tous deux de Saint-Basile, et Jean-Paul Langlois, gérant, Portneuf-Station, pour les objets suivants: Faire la confection et le commerce de vêtements de toutes sortes, sous le nom de « Confection J.E.Caron ltée », avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Saint-Basile, district judiciaire dc Québec.Le sous-mini.ilre des institut ions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.32290-o 4935-69 Confection Stc-Ursulc ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé tics lettres patentes, en date du 7e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gisèle Plante, ménagère, épouse de Jacques Garceau, 2670, rang Fontarabie, Sainte-Ursule, André Nadon, manufacturier, 1420, avenue Davidson, Montréal, et Jean-Claude Berthiaume, journalier, 2334, rue Gertrude, Chambly, pour les objets suivants: La confection et le commerce de vêtements et accessoires vestimentaires dc toutes sortes, sous le nom de «Confection Ste-Ursule ltée», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires dc $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social dc la compagnie est 2670, rang Fontarabie, Sainte-Ursule, district judiciaire dc Trois-Rivières.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290 4857-69 Corporation des Techniciens inhalo-thérapculcs du Québec Avis est donné qu'en vertu dc la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 21c jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Gilles Parent, 195, Roussillon, Laval, Joseph-Marie Fontaine, 7202, Beauchêne, et Roma Pelletier, 10257, Meritt, app.1, ces deux derniers de Montréal, tous trois techniciens, pour les objets suivants: Maintenir et améliorer les qualifications et standards des techniciens en thérapie inhalatoire, sous le nom dc « Corporation des Techniciens inhalo-tbérapeutes du Québec ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $50,000.Le siège social de la corporation est 195, Roussillon, Laval, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.ippk Bouchard.32290-o 1339-69 Leopold Dallairc liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: J.-Eudore Caron, industrialist, Louis-Marie Caron, production assistant, both of Sain I-Basile, and Jean-Paul Langlois, manager, Portneuf-Station, for the following purposes: To deal in and manufacture clothing of all kinds, under the name of \"Confection J.E.Caron ltée\", with a total capital stock of 840,001), divided into 2,000 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is al Sain I-Basile, judicial district of Québec.Ls-Phimppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 4935-09 Confection Ste-Ursule ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing (late the 7th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gisèle Plante, housewife, wife of Jacques Garceau, 2670 Rang Fontarabie, Sainto-Ursule, André Nadon, manufacturer, 1420 Davidson Avenue, Montreal, and Jean-Claude Berthiaume, labourer, 2334 Gertrude Street, Chambly, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Confection Ste-Ursule liée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 20,000 preferred shares of ?l each.The head office of the company is at 2070 Rang Fontarabie, Sainte-Ursule, judicial district of Trois-Rivières.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 4857-09 Corporation des Techniciens inhalo-thérapeutes du Québec Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date I he 21st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Gilles Parent, 195 Roussillon, Laval, Joseph-Marie Fontaine, 7202 Beauchêne, and Roma Pelletier, 10257 Meritt, Apt.1, the latter two of Montreal, all three of technicians, for the follow ing purposes: To maintain and improve the qualifications and standards of technicians in inhalation therapy, under the name of \"Corporation des Techniciens inhalo-thérapeutes du Québec\".The amount to which the value of the iininov -able property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation is at 195 Roussillon, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bo u ch a ho.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 1339-0'.; Leopold Dallairc ltée Notice is given that under Part I of I he Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of October, 1969, have been issued QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1909, Vol.101, No.61 7025 patentes, en date «lu 23e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Leopold Dallaire, entrepreneur, Yolande Duchesne, ménagère, épouse dudit Leopold Dallaire, et Lucien Dallaire, contremaître, tous trois de chemin St-Dominiquc, Jonquière, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux, sons le nom de « Leopold Dallaire ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.l.e siège social de la compagnie est chemin Saint-Dominique, Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Le mus-ministre des institut ions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32200-o 5095-69 by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Leopold Dallaire, contractor, Yolande Duchesne, housewife, wife of said Léopoltl Dallaire, and Lucien Dallaire, foreman, all three of St-Dominique Road, Jonquière, for the following purposes: To carry on business as general contractors, under the name of \"Leopold Dallaire ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at Saint-Dominique Road, Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5095-69 Deer Lake Park Inc.Parc du Lac Chevreuil inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 25e jour d'août 1969, cons-lituanten corporation: Robert Warden McKimm, Route rurale numéro 2, Lucerne, Sheldon Wiseman.38, chemin Moorcroft, tous deux avocats, Margaret Legarc, 2357, avenue Furby, et Ellen Warren, 1833, Riverside Drive, ces deux dernières secrétaires, célibataires, ces trois derniers d'Ottawa, dans la province d'Ontario, pour les objets suivants: Établir, maintenir et exploiter des lieux «le séjour, restaurants, tavernes, pavillons et cabines iKJiir touristes et tout ce qui s'y rapporte, ainsi que la pèche, la chasse, la moto-neige et autres aménagements pour loisirs, sous le nom de « Deer Lake Park Inc.\u2014 Parc du Lac Chevreuil inc.», avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 3,900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.l.e siège social «le la compagnie est à Lucerne, district judiciaire «le Hull.Le mus-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290 4151-69 Deer Lake Park Inc.Parc du Lac Chevreuil inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of August, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Robert Warden McKimm, Rural Route number 2, Lucerne, Sheldon Wiseman, 38 Moorcroft Road, both solicitors, Margaret Legarc, 2357 Furby Avenue, and Ellen Warren, 1833 Riverside Drive, the latter two secretaries, spinsters, the latter three of Ottawa, in the Province of Ontario, for the following purposes: To establish, maintain and operate resorts, restaurants, taverns, tourist lodges an«l cabins an«l all matters ancillary thereto as well as fishing, hunting, ski-doing and other recreational facilities of all kiiuls, under the name of \"Deer Lake Park Inc.\u2014 Parc du Lac Chevreuil inc.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without par value and 3,900 preferred shares of the par value of $10 each.The hea«l office of the company is at Lucerne, judicial district of Hull.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 4151-69 l-'.iliiKind Duoharme Insurance Agencies Ltd.'.vis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 28e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jacques Mochon, 9129, Louisiane, Saint-Léonard, Claude Lefebvre, 1535, Auteuil, Jean-Claude Mercure, 697, Auteuil, Claude Ouellette, 956, Frechette, tous quatre avocats, Eugène Mercure, gérant, 605, Fontainebleau, et Alain Côté, stagiaire, 177, Carignan, ces cinq derniers dc Laval, pour les objets suivants: Agir comme agents et courtiers en assurance, sous le nom dc « Edmond Ducharme Insurance Agencies Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires «le $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est ù Montréal, district judiciaire de Montréal.!¦ses: To ask for and take in money, legacies, loans with capital sunk annuity and other movable-', with a view to establish and increase a fund, under the name of \"La Fondation d'action familiale\".The amount to which is limited the annual revenue on immovables which may be held and owned by the corporation is of $100,000.The head office of the corporation is at 63S Québec Street, Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 1233-69 Gatineau Trucking (1969) ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour d'octobre 1969, Gatineau Trucking (1969) ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December SO, 1969, Vol.101, No.51 7029 constituant en corporation: Claude Bérard, Andre .lémus, tous deux de 925, boulevard Maloney est.Templeton, et Albert Bérard, 354, rue Lavio-lelto, Gatineau, tous trois hommes d'affaires, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de transport, sous le nom de « Gatineau Trucking (1969) ltée », avec un capital divisé en 10,000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 4,000 actions privilégiées de S10 chacune.l.e siège social dc la compagnie est 925, boulevard Maloney est, Templeton, district judiciaire de Hull./.c sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIILIPPE bouciiahd.:i2290-o 2596-69 Gérai in inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Gérard Alain, industriel, Jacqueline Paquet, ménagère, épouse dudit (iérard Alain, tous deux de Saint-Basile, et Jean-Guy Alain, comptable, Donnacona, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux, excavateurs et constructeurs et faire le commerce des matériaux de construction, sous le nom de « Gérolin inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.l.e siège social de la compagnie est à Saint-llasile, district judiciaire de Québec./.ecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Diane I.cgrow, housewife, wife of Jules Tessier, 189 Guillet St., Fabien St-Arnaud, trader, 121 Patry St., and Claudette Bellcmarc, secretary, spinster, of the full age of majority, 418 Boulard St., all three of Cap-dc-la-Made-leine, for the following purposes: To carry on business as licenced grocers and butchers, under the name of \"Marché Sanpri inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Cap-dc-la-Madeleine, judicial district of Trois-Rivières.Ls-Piiii.ippk BouciiAiu), Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 4712-69 Mayrosco Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de septembre 1969, constituant en corporation : Julian Kotler, 5S06, Hudson.Côte Saint-Luc, Harold W.Ashenmil, 5011, Dolbcnu, Montréal, tous deux avocats, et Rima Randolph, secrétaire, célibataire, 324, Rcdforn, Westmount, pour les objets suivants: Etablir une compagnie d'immeuble, dc construction et de placement, sous le nom dc «May-roseo Development Corp.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune et 3,000 uctions privilégiées de S10 chacune.l.e siège social de la compagnie est 2050, Mansfield, Montreal, district judiciaire de Montréal./.r sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PllIMPPE bouchard.32290 4469-69 Mayrosco Development Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of Septcmlier, 1969.have l>ecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Julian Kotler, 5806 Hudson, Côte Saint-Luc, Harold W.Ashenmil, 5911 Dolbeau, Montreal, both advocates, and Rima Randolph, secretary, spinster, 324 Rcdfern, Westmount, for the following purposes: To carry on the business of a real estutc, construction and investment company, under the name of \"Mayrosco Development Corp.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each und 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the comiiuny is ut 2050 Mansfield, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Phii.ippk Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Com panics and Cooperatives.32290-o 4469-69 ¦Metropolitan Health Spa Management Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc lu province a accordé des lettres patentes, en date du 21c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gérard Choquettc, gérant, Monique Choquettc, administrateur dc studio de santé, épouse dudit Gérard Choquettc, tous deux dc Route rurale numéro 2, Hcmming-ford, et Marifrann McCabe, secrétaire, épouse de Barry McCabe, 4662, Melrose, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des studios dc santé, des salons et aménagements d'amaigrissement pour hommes et femmes, sous le nom de « Metropolitan Health Spn Management Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de \u2022sl c-liacunc et 30,000 actions privilégiées de SI chacune.'\u2022e siège social de la compagnie est n Lu Sulle, district judiciaire de Montréal.Li- mnu-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PiiiupPE Bouchard.» 5053-69 Metropolitan Health Spa Management Inc.Notice is given that under l'art I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of Octolier, 1969, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gérurd (\"hoquette, manager, Monique Choquettc, health studio executive, wife of the said Gérard Choquettc, both of Rural Route number 2, Hemmingford, and Marifrann McCabe, secretary, wife of Barry McCabe, 4662 Melrose, Montreal, for the following purposes: To operate health studios, reducing salons und facilities for both men and women, under the name of \"Metropolitan Health Spa Management Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and 30,000 preferred shares of SI each.The head office of the company is at LoSallc, judicial district of Montreal.Ls-Piin.iiM'K Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 5053-69 7036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SO décembre 1969, 101' année, n\" 51 Montréal-Nord Flush Wood Door Inc.Portes Pleines en bois de MontréalrNord inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Barry H.Shapiro, 5367, Westmore, Earl S.Cohen, 5475, Rosedale, tous deux avocats, et Carol Partridge, secrétaire, célibataire, 2240, Madison, tous trois dc Montréal, pour les objets suivants: S'établir constructeurs et entrepreneurs généraux se spécialisant dans la fabrication et le commerce de toutes sortes de portes, fenêtres et autres matériaux de construction connexes, sous le nom de « Montréal-Nord Flush Wood Door Inc.\u2014 Portes Pleines en bois de Montréal-Nord inc.», avec un capital total de $125,000, divisé en 25,000 actions ordinaires de $1 chacune et 10,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290 4984-69 Music City (Sherbrooke) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Normand Gaumond, commerçant, Lise Bruneau, secrétaire, épouse dudit Normand Gaumond, tous deux de 1862, Rochefoucault, et Philippe Gaumond, commerçant, 139, 4e Avenue, tous trois de Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire le commerce de disques, musique en feuilles et autres marchandises semblables, sous le nom de « Music City (Sherbrooke) Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 4612-69 New Capri Restaurant Steak House Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jean-L.Guilbeault, 4180, Melrose, Jean-Pierre Bonin, 5550, Baldwin, tous deux avocats, de Montréal, et Maurice Laramée, stagiaire, 550, 25e Avenue, Pointeaux-Trembles, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants et faire le commerce d'aliments et vivres de toutes sortes, sous le nom de « New Capri Restaurant Steak House Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 10130, rue Papineau, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 5061-69 Montréal-Nord Flush Wood Door Inc.Portes Pleines en bois de Montréal-Nord inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 16th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Barry H.Shapiro, 5367 West-more, Earl S.Cohen, 5475 Rosedale, both advocates, and Carol Partridge, secretary, spinster, 2240 Madison, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders and general contractors; to manufacture and deal in all kinds of doors, windows and other similar materials of construction, under the name of \"Montréal-Nord Flush Wood Door Inc.\u2014 Portes Pleines en bois de Montréal-Nord inc.\", with a total capital stock of $125,000, divided into 25,000 common shares of $1 each and 10,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Depidy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 4984-69 Music City (Sherbrooke) Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Normand Gaumond, trader, Lise Bruneau, secretary, wife of the said Normand Gaumond, both of 1862 Rochefoucault, and Philippe Gaumond, trader, 139, 4th Avenue, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To deal in records, sheet music and other similar merchandise, under the name of \"Music City (Sherbrooke) Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Slier brookc, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 4612-0!! New Capri Restaurant Steak House Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-L.Guilbeault, 4180 Melrose, Jean-Pierre Bonin, 5550 Baldwin, both advocates of Montreal, and Maurice Laramée, articled student, 550, 25th Avenue, Pointc-aux-Trem-bles, for the following purposes: To operate hotels, taverns, inns and restaurants and to deal in food and supplies of all kinds, under the name of \"New Capri Restaurant Steak House Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 10130 Papineau Street, Montreal, judicial district of M ntrcal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 ' 5061-09 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1909, Vol.101, No.51 7037 Nirol inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour dc novembre 1969, constituant en corporation: Maurice Martel, avocat, 1301, St-Viateur ouest, Outremont, Lucille Roy, secrétaire, épouse de Jean-Claude biais, 24, rue Gilles, Sainte-Thérèse-Ouest, et Fernande Perreault, secrétaire, épouse de Paul Faquin, 10770, boulevard d'Auteuil, Montréal, pour les objets suivants: l'aire affaires comme compagnie de portefeuille, dc placement et dc gestion, sous le nom dc « Nirol inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 300 actions ordinaires de 810 chacune et en 370 actions privilégiées dc 8100 chacune.l.e siège social dc la compagnie est 3205, F.lic-Auelair, Montréal, district judiciaire dc Montréal.l.e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-e 5038-69 Nirol inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Maurice Martel, advocate, 1301 Saint-Viateur West, Outremont, Lucille Roy, secretary, wife of Jean-Claude Biais, 24 Gilles Street, Sainte-Thérèse West, and Fernande Per-reault, secretary, wife of Paul Paquin, 10770 d'Auteuil Boulevard, Montreal, for the following purposes: To carry on business as holding, investment and management company, under the name of \"Nirol inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 300 common shares of 810 each and 370 preferred shares of 8100 each._ The bead office of the company is at 3205 Elie-Auclair, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5038-69 Pauline Holdings Co.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant.-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Lucien Danscrcau, -1077.Jean Brillant, Michel Proulx, 4290, Kin-dcrsley, tous deux de Montréal, et Michel Robert, 500, Adélard, Verdun, tous trois avocats, pour les objets suivants: l'aire affaires comme compagnie dc construction et.de gestion, sous le nom de « Pauline Holdings Co.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc $10 chacune el en 2,000 actions privilégiées dc $10 chacune.l.e siège social de la compagnie est 4, rue Notre-Dame est, suite 402, Montréal, district judiciaire de Montréal./.c sous-ministre des institutions, financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-O 5162-69 Pauline Holdings Co.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Lucien Danscreau, 4977 Jean Brillant, Michel Proulx, 4290 Kindcrsley, both of Montreal, and Michel Robert, 500 Adélard, Verdun, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as a construction and management company, under the name of \"Pauline Holdings Co.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 4 Notre-Dame Street East, suite 402, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5162-69 Placements Morcna inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Savino Massari, Pasquale Del Balso, tous deux entrepreneurs, et Filoména Farinaccio, ménagère, épouse dudit Pasquale Del Balso, tous trois de 11110, Arthur Unies, Montréal-Nord, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction, de placement et dc portefeuille (holding), sous le nom de « Placements Morena inc., avec un capital total dc $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.U sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIILIPPF.'BoUCHAHD.\u2022i22110-o \" 5QS7-69 Placements Morcna inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Savino Massari, Pasquale Del Balso, both contractors, and Filoména Farinaccio, housewife, wife of said Pasquale Del Balso, all three of 11110 Arthur Buics, Montreal North, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction, investment and holding company, under the name of \"Placements Morena inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5087-69 7038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SO décembre 1969, 101' année, n\" 61 Placements Sejac inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de novembre 1969, constituant en corporation: J.-Maurice Leguer-rier, agent d'assurance, 10622, Grande-Allée, Domina Boyer, 7761, Casgrain, tous deux de Montréal, et Jean-Claude Bleau, 70, Croissant Cassino, Laval, ces deux derniers comptables, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille (holding), sous le nom de « Placements Sejac inc.», avec un capital total de 8100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 81 chacune, 1,000 actions privilégiées classe « A » de 81 chacune et en 98,000 actions privilégiées classe « B » de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Ia: sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 5204-69 Plomberie Jean ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Richard Bardeau, 275, rue Meunier, Rcpentigny, Jean Geoffrion, 30, rue Elmwood, Outremont, et Gilles Duchesne, 1169, rue Lesage, Laval, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en plomberie, chauffage et réfrigération, sous le nom dc « Plomberie Jean ltée », avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 17, rue du Crochet, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 4576-69 Placements Sejac inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: J.-Maurice Leguerrier, insurance agent, 10622 Grande-Allée, Domina Boyer, 7761 Casgrain, both of Montreal, and Jean-Claude Bleau, 70 Croissant Cassino, Laval.the latter two accountants, for the following purposes: To carry on business as a holding company, under the name of \"Placements Sejac inc.\".with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 common shares of $1 each, 1,000 preferred class \"A\" shares of $1 each and into 98,000 preferred class \"B\" shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5204-09 Plomberie Jean ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2lst day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Richard Barbeau, 275 Meunier Rcpentigny, Jean Geoffrion, 30 Elmwood Street.Outremont, and Gilles Duchesne, 1169 Lesage Street, Laval, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as plumbing, heating ami refrigeration contractors, under the name of \"Plomberie Jean ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 17 du Crochet Street, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 4570-09 Racctte Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 14c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Arthur Yanofsky, 5872, Ferncroft, Asher Kahn, 489, Dufferin, tous deux Hampstead, et Jeffrey A.Brull, 5500, Snowdon, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: S'établir compagnie de portefeuille, sous le nom de « Raccttc Holdings Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290 4939-69 Raccttc Holdings Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Arthur Yanofsky, 5872 Ferncroft, Asher Kahn, 489 Dufferin, both of Hampstead, and Jeffrey A.Brull, 5500 Snowdon, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"Raccttc Holdings Ltd.\".with a total capital stock of $40,000, divided 1,000 common shares of $10 each and 3.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 4939-69 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December SO, 1969, Vol.101, No.51 7039 Rambling Tours Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jack Sbayne, 5781, Mclling, Laurence M.Tanny, 7925, Kingsley, Ions deux de Côte Saint-Luc, Françoise Ollivier, célibataire, 200, YVillowdalc, Outremont, et Joseph Tarasofsky, 3355, Décolles, Montréal, tous les quatre avocats, pour les objets suivants: Diriger des voyages organisés de toutes natures cl de toute description, sous le nom dc « Rambling Tours Inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune cl 3.000 actions privilégiées dc S10 chacune.l.e siège social dc la compagnie est il Beacons-licld.district judiciaire de Montréal.I.r sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290 4797-69 Slack-Time Mfg.Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première pailic dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Oscar Respitz, -1915, (îlcncairn, Montréal, Sydney B.Scdcroff, SO.Crestwood, Montréal-Ouest, et Philip Shugar, 6267, MacDonald, Hampstead, tous trois avocats, pour les objets suivants: l.a confection et le commerce de vêtements de sport, de vêtements et accessoires vestimentaires de toutes sortes, sous le nom de « Slack-l'inic Mfg.Inc.», avec un capital total de $40,000, divise en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et 3,000 actions privilégiées dc $10 chacune.l.e siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal, /.c sous-ministre des instittitioris financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290 4986-69 Sun Development Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première paiiie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc In province a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Farid A.Cheftechi, 6950, avenue Fielding, app.615, John Hamilton junior, 5820, dc Louisbourg, app.26, et Ruby A.Oxncr, 3555, chemin de la Côte des Neiges, app.\u2022101, tous trois commis légistes, de Montréal, pour les objets suivants: Etablir une compagnie d'immeuble et d'expansion, sous le nom de « Sun Development Inc.», avec un capital divisé en 40,000 actions sans valeur au pair.l.e siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.32290 4949-69 Swan ton Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour de septembre 1969, constituant en corporation: Horace Friedman, Rambling Tours Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jack Shaync, 5781 Melling, Laurence M.Tanny, 7925 Kingsley, both of Côte Saint-Luc, Françoise Ollivier, spinster, 200 Willowdalc, Outremont, and Joseph Tarasofsky, 3355 Decellcs, Montreal, all four advocates, for the following purposes: To operate travel tours of any nature and description, under the name of \"Rambling Tours Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Beacons-field, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 4797-69 Slack-Time Mfg.Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Oscar Respitz, 4945 Glencairn, Montreal, Sydney B.Sedcroff, 80 Crestwood, Montreal West, and Philip Shugar, 6267 Mac-Donald, Hampstead, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in sportswear, clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Slack-Time Mfg.Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The bead office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 4986-69 Sun Development Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Farid A.Cheftechi, 6950 Fielding Avenue, Apt.615, John Hamilton junior, 5820 de Louisbourg, Apt.26, and Ruby A.Oxner, 3555 Côte des Neiges Road, Apt.401, all three law clerks, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and development company, under the name of \"Sun Development Inc.\", with a capital stock divided into 40,000 shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 4949-69 Swan ton Investment Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Horace Friedman, 7497 Briar 7040 GAZETTK OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 décembre 1969, 101' année, n' ùl 7497, chemin Briar, Barry A.Cappel, 5891, Centennial, tous deux de Côte Saint-Luc, et Boris J.Berbrier, 4851, rue Fulton, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir une compagnie dc placement, sous le nom de « Swanton Investment Corp.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290 3539-69 Road, Barry A.Cappel, 5891 Centennial, both of Côte Saint-Luc, and Boris J.Berbrier, 4X51 Fulton Street, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Swanton Investment Corp.\", with a total capital stock of $ 10,000.divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 3539-00 Trans-Canada Roofing Company Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Oscar Cobcnc, entrepreneur couvreur, Grace Cobcnc, ménagère, épouse dudit Oscar Cobcnc, tous deux du 5727, Mclling, Côte Saint-Luc, et Joseph Cohene, gérant, 1593, Cardinal, Saint-Lnurent, pour les objets suivants: S'établir entrepreneurs et constructeurs et fabriquer des préparations pour faire des toits ainsi que des bardeaux de toutes sortes, «le bois ou d'autre matériau, sous le nom «le « Trans-('an m la Roofing Company», avec un capital total de S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées dc $1 chacune Le siège social dc la compagnie est 3734, Dc Bullion, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290 4172-69 Trc Ga Ro inc.Avis est donné qu'en vertu dc lu première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 24c jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Paul-Henri Tremblay, administrateur, 140, boulevard Central, Maurice Gauvin, gérant d'usine, 2024, Lemicux, tous deux «le Dubergcr, et Jean-Marie Robitaillc, chef «le service, 1426, Place des Bretons, Orsainville, pour les objets suivants: Faire le commerce de la viande, sous le nom de «Trc Ga Ro inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 800, 8e Avenue, Charny, district judiciaire dc Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 5127-69 Trans-Canada Roofing Company Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2n«l day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Oscar Cohene, roofing contractor, (iracc Cohene, housewife, wife of the said Oscar Cohene, both of 5727 Mclling, Côte Saint-Luc, and Joseph Cohene, manager, 1593 Cardinal.Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on business as contractors and builders and to manufacture roofing preparations und shingles of all kinds, whether of wood or any other material, under the name of \"Trans-Canada Roofing Company\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each und 30,000 preferred shares of $1 each.The bend ollicc of the company is at 3731 Dc Bullion, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 4172-69 Trc Ga Ro inc.Notice is given that under Part I of I he Companies Act, letters patent, bearing dale the 24th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul-Henri Tremblay, administrator, 140 Central Boulevard, Maurice Gauvin.plnnt manager, 2024 Lemieux, both of Dubergcr, and Jean-Marie Robitaillc, department head, 1426 Place des Bretons, Orsainville, for the following purposes: To deal in meat, under the name of \"Trc Go Ro inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head ollicc of the company is ut 800, 8th Avenue, Charny, judicial district of Quebec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Ministcr of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5127-09 Trois-Rivicrcs estimation inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie dc la Loi des (compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 24c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Pierre Mostert, dessinateur, Dcnyse Mestrez, ménagère, épouse dudit Pierre Mosterl, tous deux de 1185, de Trois-Rivières estimation inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province incorporating: Pierre Mostert, draftsman, Dc-nys s Mestrez, housewife, wife of said Pierre Mostert, both of 1185 de l'Espérunto, and Jean QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, I960, Vol.101, No.51 |'l>|)cranto, et Jean Paradis, technicien, 872, Panneton, tous trois de Trois-Rivières, pour les ohrjts suivants: exploiter un bureau d'estimation consistant à fournir les services techniques en construction et estimation, sous le nom de « Trois-Rivières estimation inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.be siège social de la compagnie est 1185, de l'Espéranto, Trois-Rivières, district judiciaire dc Trois-Rivières.I.e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopérantes, Ls-Philippe Bouchard.32290-e 4657-69 Union des Gradués Inscrits a Laval (U.G.LL.) inc.Avis est donné qu'en vertu dc la troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres intentes, en date du 30c jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: René-Paul Foumier, 3030, LcChasscur, Marcel Guay, 789, Chanoine Groulx, tous deux chimistes.Robert Tanguay, biochimiste, 3022, LcChas-scur, et Benoit Turner, physicien, 1102, Dijon, app.7, tous quatre dc Sainte-Foy, pour les objets suivants: Etudier, promouvoir, protéger et développer de toutes manières les intérêts économiques, sociaux et professionnels des membres, sous le nom i des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres intentes supplémentaires en date du 1 le jour dc septembre 1969, à la compagnie « Chcmco Ltd.\u2014 Chcmco ltée», 1° diminuant son capital de S250.0Q0 ù §150,000, le capital-actions annulé devant être divisé en ÎO.OOO actions ordinaires non émises d'une valeur au pair de $10 chacune; 2° subdivisant 5,000 actions ordinaires d'une valeur nu pair de $10 chacune en 50,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune; 3° augmentant son capital dc $150,000 à $450,000, le capital-actions additionnel devant être divisé en 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.32290 1857-69 \u2014 1507/53 Drakcstonc Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Loi des compagnies, le lieutenunt-gouverneur de lu province a accordé des lettres patentes supplémentaires en «latc du 19e jour de Association Québécoise dc Judo Kodokan inc.Notice is given that, umlcr the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 6th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Association des Ceintures Noires de Judo Kodokan du Québec \u2014 Québec Kodoknn Judo Black Belt Association\", incorporated by letters patent dated the 28th day of November, 1966, changing its name to that of \"Association Québécoise de Juilo Kodokan inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 4595-66 \u2014 1517 71 Chcmco Ltd.Chcmco liée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 11th «lay of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province to \"Chemco Ltd.\u2014 Chcmco ltée\", 1.reducing its capital from $250,000 to $150,000.the capital stock annulled being divided into 10,0011 unissued common shares of the par value of $10 each; 2.subdividing 5,000 common shares of the par value of $10 each into 50,000 common shares of the par value of $1 each; 3.increasing its capital from $150,009 lo S4?0-000: 1,10 tional capital stock being divided into 3.00\" preferred shares of the pur value of $100 each.Albert Jessop, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 1857-09 \u2014 1507 â:< Drukcstonc Corporation Notice is given thut, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor »f QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1969, Vol.101, No.51 7043 septembre 1969, à lu compagnie « Drakestone Corporation », 1° subdivisant et redésignant 5,000 actions sans valeur nominale ou valeur au pair en 9,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou valeur au pair; 2° augmentant son capital par la création de 16,890 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.l.e sous-ministre des institut'ionsfinancières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.32290 6296-47 \u20141517/81 Les Entreprises Fcrnand Seguin inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 21e jour de murs 1969, à la compagnie « Le Sel dc la Semaine inc.», constituée par lettres patentes en date du 9e jourde janvier 1969, changeant son nom en celui de « Les Entreprises Fernand Seguin inc.»./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 146-69\u20141518/48 Friendly Wood Gatineau Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres intentes supplémentaires en date du 30e jour d'octobre 1969, ù la compagnie * Friendly Wood Gatineau Ltd.», convertissant 20,000 actions ordinaires non émises sans valeur nominale ou valeur au pair en 20,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc SI chacune.l.e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290 1144-66\u2014 1517/25 Le Groupe Sécurité inc.The Security Group Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 6e jour dc novembre 1969, ù la compagnie « Le Groupe Sécurité inc.\u2014 The Security Group Inc.», augmentant son capital de $450,000 ù $1,000,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 2,900 allions ordinaires dc $100 chacune, 1,000 actions privilégiées classe « A » dc $100 chacune, 1,000 actions privilégiées classe « B » dc $100 chacune et en 600 actions privilégiées classe « C » de '.:\"0 chacune.l.e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 159-67\u2014 1517/106 Immeubles E.P.R.ltée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 19e jour de septembre 1969, à la compagnie « Édifice Place Royale (Trois-Rivières) inc.», constituée par lettres patentes en date du 8e jour de juillet 1964, changeant son nom en celui de « Immeubles Kl'.R.ltée».I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 2836-64 \u20141517/62 the Province to \"Drakestone Corporation\", 1.subdividing and redesignating 5,000 shares without nominal or par value into 9,000 common shares without nominal or par value; 2.increasing its capital by the creation of 16,890 preferred shares of the par value of $100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 6296-47 \u2014 1517/81 Les Entreprises Fernand Seguin inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of March, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Le Sel de la Semaine inc.\", incorporated by letters patent dated the 9th day of January, 1969, changing its name to that of \"Les Entreprises Fernand Seguin inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 146-69 \u20141518/48 Friendly Wood Gatineau Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Friendly Wood Gatineau Ltd.\", converting 20,000 unissued common shares without nominal or par value into 20,000 preferred shares of the par value of $1 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 1144-66\u20141517/25 Le Groupe Sécurité inc.The Security Group Inc.* Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 6th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Le Groupe Sécurité inc.\u2014 The Security Group Inc.\", increasing its capital from $450,000 to $1,000,000, the additional capital shares being divided into 2,900 common shares of $100 each, 1.000 preferred class \"A\" shares of $100 each, 1,000 preferred class \"B\" shares of $100 each and into 600 preferred class class \"C\" shares of $100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 159-67 \u20141517/106 Immeubles E.P.R.ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Édifice Place Royale (Trois-Rivières) inc.\", incorporated by letters patent dated 8th day of July, 1964, changing its name to that of \"Immeubles E.P.R.ltée ».Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 283Q-64 \u20141517/62 7044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 décembre 1969, 101' année, n° 51 Index Holdings & Management Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le licutenant-gouveerneur dc la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 10c jour d'octobre 1969, à la compagnie « Index Holdings & Management Ltd.», augmentant son capital de 8100,000 à 85,200,000, le capital-actions additionnel devant être divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc 810 chacune et 500,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290 5365-68 \u20141517/107 Index Holdings & Management Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters paten!, bearing date the 10th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Index Holdings & Management Ltd.\", increasing its capital from 8100,000 to 85,200,000, the additional capital stock being divided into 10,000 common shares of the par value of S10 each and 500,000 preferred shares of the par value of 810 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 5365-68 \u2014 1517/107 Industries Brunelle inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 6e jour de novembre 1969, à la compagnie « Henri-Louis Brunelle inc.», constituée par lettres patentes en date du 31e jour d'octobre 1963, 1° changeant son nom en celui de « Industries Brunelle inc.» ; 2° subdivisant ses 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune; 3° augmentant son capital de 840,000 à S190.100, le capital-actions additionnel étant divisé en 100 actions privilégiées classe « A» de $1 chacune et en 1,500 actions privilégiées classe « B » dc $100 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 4691-63 \u20141518/69 Industries Brunelle inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters paten I.bearing date the 6th day of November, 1909.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Henri-Louis Brunelle inc.\", incorporated by letters patent dated the 31 si day of October, 1963, 1.changing its name to that of \"Industries Brunelle inc.\"; 2.subdividing its 400 common shares of a par value of 8100 each into 4,000 common shares of $10 each; 3.increasing its capital stock from $40,000 to $190,100, the additional share capital being divided into 100 preferred class \"A\" shares of SI each and 1,500 preferred class \"B\" shares of $100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 4691-63\u2014 1518.69 Inter Continental Equipment and Supply Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour d'octobre 1969, à la compagnie « Inter Continental Equipment and Supply Co.Ltd.», augmentant son capital de $10,000 à $110,000, le capital-actions additionnel devant être divisé en 10,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc 810 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290 11497-55 \u2014 1517/87 Inter Continental Equipment and Supply Co.Ltd.Notice is given that, under Part I of I he Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of October, 1909.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Inter Continental Equip: ment and Supply Co.Ltd.\", increasing its capital from 810,000 to 8110,000, the additional capital stock being divided into 10,000 preferred shares of the par value of $10 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 11497-55 \u2014 1517/N7 La Ligue de Hockey Junior « B » Provinciale du Québec inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province, des lettres patentes supplémentaires en date du 22e jour dc septembre 1969, à la corporation « La Ligue de Hockey Junior «_B » de la Mauricic inc.», constituée en corporation par lettres patentes du ISe jour de novembre 1968, changeant son nom en celui dc « La Ligue de Hockey Junior « B » Provinciale du Québec inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 5029-68 \u2014 1509/54 La Ligue dc Hockey Junior \"B\" Provinciale du Québec inc.Notice is given that, under the Companies Act, supplementary letters patent, bearing dale the 22nd day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"La Ligue de Hockey Junior \"B\" dc la Mauricic inc.\", incorporated by letters patent dated the 18th day of November, 190\\ changing its name to that of \"La Ligue de Hockey Junior \"B\" Provinciale du Québec inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 5029-68 \u2014 1509/5 ! QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December SO, 1909, Vol.101, No.51 7045 Lubri-Val inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 3c jour de novembre 1969, à la compagnie « Lubri-Val inc.\", augmentant son capital dc $40,000 à §150,000, par la création dc 1,100 actions privilégiées d'une valeur au pair dc $100 chacune, /.c mis-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 3071-65 \u20141518/74 Lubri-Val inc.Notice is given that, under Part I of the Act, supplementary letters patent, bearing date the 3rd day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Lubri-Val inc.\", increasing its capital stock from $40,000 to $150,000, by the creation of 1,100 preferred shares of a par value of $100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 3071-65\u20141518/74 Maison Pic XII Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 17e jour de septembre 1969, à la corporation « Maison Pic XII », étendant ses pouvoirs, et ce, par l'augmentation du montant auquel sout limités les biens immobiliers que peut acquérir et posséder ladite corporation dc $200,-1100 à $2,000,000./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 14119-60\u20141508/90 Maison Pic XII Notice is given that, under the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 17th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Maison Pie XII\", extending its powers, and such, by increasing the amount to which are limited the immovables which may be held or owned by the corporation from $200,000 to $2,000,000.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 14119-60 \u20141508-90 Jules St-Picrre lt«5c Avis est donné qu'en vertu de la première pailic de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 1er jour d'octobre 1969, à la compagnie « Jules St-Pierrc liée», modifiant les droits, privilèges et restrie-lions afférents aux actions privilégiées, /.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 10455-57 \u2014 1518/40 Service Super Sports ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 13c jour d'août 1969, n lu compagnie « Les Sports motorisés de Jonquière ltée», constituée par lettres palentes en date du 23e jour de mai 1969, changeant son nom en celui dc « Service Super Spoils liée »./a sous-ministre des institidions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 2275-69 \u20141518/87 Société Drassel inc.Drasscl Corporation Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 6c jour dc novembre 1969, à la « Société Drasscl inc.\u2014 Drassel Corporation Inc.», modifiant les dispositions de ses lettres patentes, /.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290>o 1963-67 \u2014 1518/39 Jules St-Picrrc ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 1st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Jules St-Pierre ltée\", amending the rights, privileges and restrictions attached to its preferred shares.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 10455-57 \u20141518/40 Service Super Sports ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 13th day of August, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Les Sports motorisés de Jonquière ltée\", incorporated by letters patent dated the 23rd day of May, 1969, changing its name to that of \"Service Super Sports ltée\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 2275-69 \u20141518/87 Société Drassel inc.Drasscl Corporation Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 6th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Société Drassel inc.\u2014 Drassel Corporation Inc.\", amending the provisions of its letters patent.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 1963-67 \u20141518/39 7046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SO décembre 1969, 101' année, n\" 51 Toulon Construction Inc.Avis est donne qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 22e jour dc septembre 1969, à la compagnie « Toulon Construction Inc.», augmentant son capital de 320,000 à $120,000, le capital-actions additionnel devant être divisé en 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290 13152-61 \u20141518/42 Victoriavillc Furniture Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 3e jour de novembre 1969, à la compagnie « Victoriavillc Furniture Limited », 1° subdivisant 990 actions ordinaires d'une valeur au pair dc $100 chacune en 99,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc $1 chacune; 2° augmentant son capital par la création dc 11,000 actions ordinaires additionnelles d'une valeur au pair de $1 chacune et dc 1,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 553-20 \u2014 1518/46 Toulon Construction Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters paten I, bearing date the 22nd day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Toulon Construction Inc.\", increasing its capital from S20.000 to 8120,000, the additional capital stock being divided into 1,000 preferred shares of the par value of $100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.32290-o 13152-61 \u2014151S,-12 Victoriaville Furniture Limited Notice is given that, under Part I of I lie Companies Act, supplementary letters liaient, bearing date the 3rd day of November, 1909, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Victoriavillc Furniture Limited\", 1.subdividing 990 common shares of a par value of $100 each into 99,000 common shares of a par value of $1 each; 2.increasing its capital stock by the creation of 11,000 additional common shares of a par value of $1 each and 1,500 preferred shares of a par value of $100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 553-20 \u2014151S.lt) Compagnies dissoutes Companies Dissolved A.& P.Boisvert ltée \u2014 Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives d'accepter l'abandon de charte de « A.& P.Boisvert ltée \u2014 Ltd.», constituée en corporation le 13 octobre 1955, à compter du 9 décembre 1969.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 12762-55 Le Club des 24 inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives d'accepter l'abandon de charte «le « Le Club des 24 inc.», constituée en corporation le 16 février 1908, à compter du 9 décembre 1969.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32290-o 576-68 A.& P.Boisvert Itce \u2014 Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"A.& P.Boisvert ltée \u2014 Ltd.\", incorporated on October 13, 1955, on and from December 9, 1969.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 12762-55 Le Club des 24 inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased lo ucccpt the surrender of the charter of \"Le Club des 24 inc.\", incorporated on February 16.1968, on und from December 9, 1969.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290 576-68 Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions Caisse d'économie des Travailleurs de Rimouski (ImI des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a approuvé la formation de la caisse d'épargne et de crédit: « Caisse d'économie des Travailleurs de Rimouski ».Caisse d'économie des Travailleurs dc Rimouski (Savings and Credit Unions Act) Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of the savings and credit union \"Caisse d'économie des Travailleurs de Rimouski\". QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1969, Vol.101, No.51 7047 Le territoire dans lequel la caisse recrutera ses membres, sera: la ville de Rimouski.Le siège social de cette caisse d'épargne et de crédit est situé dans la ville de Rimouski, Québec, dims le district electoral de Rimouski.Québec, le 26 novembre 1969.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 32304-o Ls-Philippe Bouchard.Caisse populaire des enseignants de Baie des Chaleurs (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation de la caisse d'épargne et de crédit: « Caisse populaire des enseignants de Haie des Chaleurs ».Le groupe dans lequel la caisse recrutera ses membres, sera: l'Association des enseignants de la Haie des Chaleurs.Le siège social de cette caisse d'épargne et de crédit est situé à Caplan, Québec, dans le district électoral dc Bonaventure.Québec, le 29 octobre 1969./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 32305-o Ls-Philippe Bouchard.La Caisse populaire des employés fédéraux de l'est du Québec (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donne que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation dc la caisse d'épargne et de crédit: « La Caisse populaire des employés fédéraux de l'est du Québec ».Le groupe dans lequel la caisse recrutera ses membres, sera: Les employés permanents fédéraux et dc « L'Alliance de la Fonction Publique du Canada » de l'est dii Québec, (régions administratives de Québec, Chicoutimi, Côte Nord, lias St-Luurent et Gaspésie).Le siège social dc cette caisse d'épargne et de crédit est situé dans la ville de Québec, Québec, dans le district électoral de Jean-Talon.Québec, le 16 octobre 1969.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 32340-o Ls-Philippe Bouchard.The territory from which the union will recruit its members will be: the city of Rimouski.The head office of this savings and credit union is situated in the city of Rimouski, Québec, in the electoral district of Rimouski.Québec, November 26, 1969.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 32304 Companies and Cooperatives.Caisse populaire des enseignants de Baie des Chaleurs (Savings and Credit Unions Act) Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of the savings and credit union: \"Caisse populaire des enseignants de Baie des Chaleurs\".The group from which the union will recruit its members will be: l'Association des enseignants dc la Baie des Chaleurs.The head office of this savings and credit union is situated at Caplan, Québec, in the electoral district of Bonaventure.Québec, October 29, 1969.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 32305 Companies and Cooperatives.La Caisse populaire des employés fédéraux de l'est du Québec (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Inctitutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of the savings and credit union: \"La Caisse populaire des employés fédéraux de l'est du Québec\".The group from which the union will recruit' its members will be permanent federal employees and \"L'Alliance de la Fonction Publique du Canada\" of Eastern Québec (administrative areas of Québec, Chicoutimi, the North Shore, Lower Saint Lawrence and Gaspesia).The head office of the said savings and credit union is situated in the city of Québec, Québec, in the electoral district of Jean-Talon.Québec, October 16, 1969.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 32340 Companies and Cooperatives.Chartes \u2014 demandes d'abandon de Jos Bélanger ltée Prenez avis que la compagnie « Jos Bélanger liée »,^ demandera au ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives la permission d'abandonner sa charte.Le secrétaire, °2317-o Robert Joachim.B.& P.Painters & Decorators Ltd.Avis est par les présentes donné que « B.& P.lainters & Decorators Ltd.», ayant son siège social en la ville de Montréal, en la province de Québec, demandera la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 29e jour de juillet 1969.Les procureurs de la requérante, Leciiter & Segal.Charters \u2014 Application for Surrender of Jos Bélanger ltée Notice is given that the \"Jos Bélanger ltée\", company will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Robert Joachim, 32317-0 Secretary.B.& P.Painters & Decorators Ltd.Notice is hereby given that \"B.& P.Painters & Decorators Ltd.\", which has its head office in the city of Montreal, in the Province of Québec, will make application for leave to surrender its charter in accordance with the provisions of the Companies Act.Montreal, the 29th day of July, 1969.Leciiter & Segal, 32318-0 Attorneys for the Petitioner. 7048 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SO décembre 1969, 101' année, n\" 51 Brosc Industries Ltd.Avis est par les présentes donné que « Brosc Industries Ltd.», ayant son siège social en la ville de Montréal, en la province de Québec, demandera la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 29e jour de septembre 1969.Les procureurs de la requérante, 32319 Leciiter & Secal.Capri Development Inc.Avis est par les présentes donné que « Capri Development Inc.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 28e jour de novembre 1969.Le secrétaire, 32320 Melvin Neumaiik.Lakeside Gardens Inc.Avis est donné que « Lakeside Gardens Inc.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social à Montréal, Québec, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions dc lu Loi des compagnies.Daté à Montréul, ce 5e jour de décembre 1969.Les procureurs de la compagnie, Kaufman, Resi'itz, Sederoff 32321 & Siiuwar.McNicolI & Frères ltée Prenez avis que la compagnie « McNicolI & Frères ltée », ayant son siège social dans la cité de Charlcsbourg, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission «l'abandonner sa charte.Courville, ce 2 décembre 1969.Le procureur de la compagnie, 32322-0 Adrien Grenier, notaire.Monkland Construction Inc.Prenez avis que la compagnie « Monkland Construction Inc.», demandera au'ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 32324-o Me Guy Lacoste, notaire.Rose Gardens Convalescent & Nursing Home Inc.Avis est par les présentes donné que « Rose Gardens Convalescent & Nursing Home Inc.», ayant son siège social en la ville dc Montréal, en la province dc Québec, demandera la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 16e jour de septembre 1969.Les procureurs de la requérante, 32326 Leciiter & Segal.Brosc Industries Ltd.Notice is hereby given that \"Brosc Industries Ltd.which has its head office in the city of Montréal, in the Province of Québec, will make application for leave to surrender its charter in accordance with the provisions of the Companies Act.Montréal, the 29th day of September, 1969.Leciiter & Segal, 32319-0 Attorneys for the Petitioner.Capri Development Inc.Notice is hereby given that \"Capri Development Inc.\", incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 28th day of November, 1969.Melvin Neumark, 32320-o Secretary.Lakeside Gardens Inc.Take notice that \"Lakeside Gardens Inc.\", a company incorporated under the Companies Act, and having its head office at Montreal.Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter, under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 5th day of December, 1969.Kaufman, Respitz, Sedeuoff & SlIUGAR, 32321 -o Attorneys for the Company.McNicolI & Frères liée Notice is hereby given that \"McNicolI & Frères ltée\", having its head office in the city of Charlcsbourg, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Courville, on December 2, 1969.Adrien Grenier, nolary, 32322-o Attorney for the Com pany.Monkland Construction Inc.Notice is given that \"Monkland Construction Inc.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Me Guy Lacoste, notary, 32324 Altorneyfor the Compan>j.Rose Gardens Convalescent & Nursing Home Inc.Notice is hereby given that \"Rose Gardens Convalescent & Nursing Home Inc.\", which has its bead office in the city of Montreal, in the province of Québec, will make application for leave to surrender its charter in accordance with the provisions of the Companies Act.Montreal, the 16th day of September, 1969.Leciiter & Segal, 32326-o Attorneys for petitioner. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1969, Vol.101, No.51 7049 Metropolitan Builders Development Corp.Metropolitan Builders Development Corp.Avis est par les présentes donné que « Metropolitan Builders Development Corp.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province dc Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions dc ladite Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 5e jour de décembre I'M.Leu procureurs de la requérante, 32323-0 Greenblatt, Godinsky & Resin.Nadco Investments Inc.Avis est donné que « Nadco Investments Inc.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la cité dc Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 3e jour de décembre 1969.Les procureurs, 32325-0 Gurman, Marcovitch & Miller.Tru-Lite (Montreal) Inc.Avis est par les présentes donné que « Tru-Lite (Montréal) Inc.», une corporation constituée en vertu dc la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.1 )até à Montréal, ce 28c jour de novembre 1969.32:527 Le secrétaire, Alois L.Factor.George A.Watson (Québec) Limited Prenez, avis que la compagnie « George A.Watson (Québec) Limited », a l'intention de s'adresser au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Le président, 32328-0 Arnold F.Stevenson.Au Grand Salon ltée IV.nez avis que la compagnie « Au Grand Salon ltée », demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 10e jour de décembre 1969.Us procureurs de la compagnie.Paré, Barbeau, Holden, \"2341-0 Steinberg & Dermer.Tri-Nol Inc.'\u2022Venez avis que la compagnie « Tri-Nol Inc.», ayant son siège social à 865, 1ère Avenue,Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte en vertu des Dispositions de la Loi des compagnies.Le procureur de la compagnie, '\"¦Jlo\"° Michel Brocuu.Notice is hereby given that \"Metropolitan Builders Development Corp.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of said Companies Act.Dated at Montreal, this 5th day of December, 1969.Greenblatt, Godinsky & Resin, 32323-0 Attorneys for the Applicant.Nadco Investments Inc.Notice is hereby given that \"Nadco Investments Inc.\", a corporation, incorporated under the Companies Act, and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 3rd day of December, 1969.Gurman, Marcovitch & Miller, 32325-0 Attorneys.Tin-Lite (Montreal) Inc.Notice is hereby given that \"Tru-Litc (Montreal) Inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter under the Companies Act.Dated at Montreal, this 28th day of November, 1969.Alois L.Factor, 22327-o Secretary.George A.Watson (Québec) Limited Take notice that \"George A.Watson (Québec) Limited\", intends to apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Arnold F.Stevenson, 32328-0 President.Au Grand Salon ltée Notice is hereby given that \"Au Grand Salon ltée\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, this 10th day of December, 1969.Pare, Barbeau, Holden, Steinbero & Dermer, 32341-o Attorneys for the Company.Tri-Nol Inc.Notice is given that \"Tri-Nol Inc.\", having its head office at 685, 1st Avenue, Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter pursuant to the provisions of the Companies Act.Michel Brochu, 32345 Attorney for the Company. 7050 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SO décembre 1969, 101' année, n\" 51 Cummings Continental Car Corp.Avis est par les présentes donné que « Cummings Continental Car Corp.», une corporation constituée en vertu dc la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce lie jour dc décembre 1909.Le procureur de la compagnie, 32342 Monroe Abbey, ch.Kampus Record & Book Shops Inc.Avis est donné que « Kampus Record & Book Shops Inc.», une corporation ayant son siège social dans la cité de Côte St-Luc, district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives dc la province de Québec afin d'obtenir la permission «l'abandonner sa charte, conformément aux dispositions dc la Loi des compagnies.Le procureur de la compagnie, 32343-o Simon Richter.St.Joseph's House of Hospitality Inc.Avis est par les présentes donné que « St.Joseph's House of Hospitality Inc.», une corporation constituée en vertu de la troisième partie «le la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, province dc Québec, s'adressera au ministre «les institutions financières, compagnies et coopératives afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de ladite Loi.Daté à Montréal, Québec, ce 10e jour dc décembre 1969.lies procureurs de la corporation, Stewart, McKenna, Wagner, 32344 Lefebvre, Loriot & Phelan.Universal Feeds Limited Avis est donné que la compagnie « Universal Feeds Limited», une corporation incorporée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives dc la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 5e jour «le décembre 1969.Les procureurs de la compagnie, Prévost, Trudeau, Bisaillon 32346-o & Leduc.Cummings Continental Car Corp.Notice is hereby given that \"Cummings Continental Car Corp.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to I lie Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Datetl at Montreal, this 11th day of December, 1969.Monroe Abbey-, q.c, 32342-o Altorneyfor the Company.Kampus Record & Book Shops Inc.Notice is hereby given that \"Kampus Record & Book Shops Inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act an«l having its head office in the city of Côte St-Luc, district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Simon Richteii, 32343-0 Attorney for the Company.St.Joseph's House of Hospitality Inc.Notice is hereby given that \"St.Joseph's House of Hospitality Inc.\", a corporation having a charter under Part III of the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the said Act.Dated at Montreal, Québec, this 10th day of December, 1969.Stewart, McKenna, Wagner, Lefebvre, Loriot & Phelan, 32344-o Attorneys for the corporation.Universal Feeds Limited Notice is hereby given that \"Universal Feeds Limited\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave lo surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 5th , (lot 304, subdivision \"j, au sud-ouest et au nord-ouest par le lot 304 subdivision 3, au sud-est par le lot 304 subdivision 2 cl ii l'arrière par le lot 305 du cadastre officiel dc la paroisse de St-Bruno.MM Trilon Construction Co.Ltd., 8235 Mountain Sights Ave, Montreal, Que.TU) l'ouliot, Gaston, 0 rue Olier, Saint-Basile-le-Grand, Que.l'artie sud-est du lot No 307-20 du cadastre de la punisse de St-Bruno, mesurant (10') de largeur sur une profondeur de (102'); borné: en front, au nord-est par le boulevard Taillon; en arrière, au sud-ouest, par partie «lu hit 300 on ses subdivisions; auxdits plan et livre de rei \u2022 i officiels; d'un côté, nu nord-ouest, par le résidu tic I tditc subdivision 20 dudit lot; et de l'autre côté au suilest, par la subdivision 28 dudit lot ci-dessus décrit, nie tire anglaise.Sans bâtisse.2200 22112 2200 2270 2282 22SI 2285 22S7 Trilon Construction Co.Ltd.8325 Mountain Sights Ave.Montreal, Que____ Elite Investment Corporation, c'o Garmuiso & Garmaise, 1010 Ste-Catherine West, Montreal Que.Trilon Construction Go.Ltd., 8235 Mountain Sights Ave, Montreal, Que.Trilon Construction Co.Ltd., 8235 Mountain Sights Ave, Montreal, Que.Trilon Construction Co.Ltd., 8235 Mountain Sights Ave, Montreal, Que- Trilon Construction Co.Ltd., _ 8235 Mountain Sights Ave, Montreal, Que.Trilon Construction Co.Ltd., 8235 Mountain Sights Ave, Montreal, Que- Trilon Construction Co.Ltd., 8235 Mountain Sights Ave, Montreal, Que.,.301.I'.3.Lot 301-P.3 \u2014 l'arish of St.Bruno, with building bearing civic number 310 of said Hang des Vingt, to withdraw, the southwest part measuring (55') in width by a depth of (144.2') on one line and (142.7') on the other line, and having a superficies of (7.800 sq.ft.), net no.200410.301.I'.304.l'art of lot 394\u2014 Parish of St.Bruno, measuring (70') in front, by (100') in depth on its northwest and southeast lines, and hounded in front, by the said street called \"Ménard\" (lot number 304, subdivision 7), to the southwest and to the northwest by the lot number 304 subdivision 3, and to the southeast by the lot 304 subdivision 2, and in the rear by the lot 395 of the said cadastre of the parish of St.Bruno.304.0.307 .28 et-and I'.20.Southeast part of lot number 307-29 of cadastre of the parish of St.Bruno, measring (10') in width by a depth of (102'); bounded; in front, to northeast by the boulevard Taillon, in rear to the southwest, by a part of the lot number 390 or its subdivisions, on the said official plan and book of reference; on one side, to the northwest, by the residue of the said subdivision 29 of the said lot; on the other side, to the southeast, by the subdivision 28 of the said lot under described, English measures.Without building.403.121.403.117.404.40.403, 404.100.59.404.02.404 .04.404 .05.403,404.119.07. 7052 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 décembre 1969, 101' année, n' 51 Les immeubles susdits sont tous aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Bruno, maintenant ville de Saint-Basile-le-Grand et situés dans ladite ville, le bureau d'enregistrement de la ville est situé au 201 place Charles LeMoyne, Longueuil.Ladite vente sera en outre faite avec tous les droits de subrogation, toutes les servitudes actives ou passives apparentes ou occultes attachées auxdits immeubles.Donné en la ville de Saint-Basile-le-Grand, ce douzième jour de décembre mil neuf cent soixante-neuf.(Sceau) Le secrétaire-trésorier, 32336-51-2-0 Martial Lalande.Cité de Jonquière Avis public est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la cité de Jonquière, que les immeubles ci-dessous désignés seront vendus à l'enchère publique à PHôtel-de-Ville de la cité de Jonquière, 320 rue S t- Do m inique, Jonquière, MARDI, le DIX-SEPTIÈME jour de FÉVRIER de l'an mil neuf cent soixante-dix, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires ainsi que les intérêts et frais subséquents encourus à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.The above immovables are all on the plan und book of reference of the parish of St-Bruno, now town of Saint-Basile-le-Grand and situated in the said town, the registration office of the said town is situated at 201 Place Charles LeMoyne, Longueuil.The said sale will be made with all subrogation rights, and all active and passive servitudes, apparent or occult attached to the said properties.Given at the town of Saint-Basile-le-Grand, this twelfth day of December, nineteen hundred and sixty-nine.32336-51-2-0 Martial Lalande, (Seal) Secretary-Treasurer.City of Jonquière Public notice is hereby given by the undcr-gned, City Clerk of the city of Jonquière, that hereinafter described immovables will be sold by public auction, at the City Hall of the city of Jonquière, TUESDAY, the SEVENTEENTH day of FEBRUARY in the year nineteen seventy, at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy to the payment of Municipal and School taxes with accrued interests and costs incurred thereon unless the said taxes, interests and costs be paid before the sale.Numéro du compte Account number 4-3-2-0.4-7-4-7.4-9-14-14.1-1-1-0.NomB des propriétaires et adresses Names of proprietors and addresses Mme Arthur Desbiens, 00 St-Laurent, Jonquière, P.Q.M.Alfred Deveau.10a Laval.Kénogami, P.Q.MM.Real Nault & Robert Côté, 217 Panet, Jonquière, P.Q.M.Joseph Larouche, 402 St-Jean-Baptiste, Jonquière, P.Q.Description de l'immeuble Description of immovable Lot 20-B-347, R.III.Lot 25-A-302, It.III.Lot 25-A-308, R.III.1'.a) Toute cette partie sud-ouest du lot numéro dix-huit (Ptie S.-O.No 18), du rang trois (Rg III) du cadastre officiel du canton Jonquière, mesurant environ un arpent de largeur en front sur la rue St-Jean-Baptiste sur une profondeur de cent pieds (100') do l'est A l'ouest et bornée vers le nord par le résidu du lot, propriété de M.Donat Gagnon ou représentants, vers l'est par une partie résiduelle dudit lot appartenant a Price Brothers Co.Ltd., vers le sud par cette partie du lot dix-neuf-B (Ptie lot No 10-B) ci-après décrite et vers l'ouest par la rue St-Jean-Baptiste actuelle; et 'c deducted a part of said lot sold ns appears number 301405. 7062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SO décembre 1969, 101' année, n\" 61 Une partie du lot 204 ayant une superficie approximative de 11.00 arpents et plus ou moins, bornée comme suit: au sud-est par la rue De Touraine, au nord-est pur une partie du lot 204, au sud-ouest pur une partie du lot 205 et au nord-ouest par une partie des lots 100 et 122.A part of lot 204 containing on area of approximately 11.00 acres, more or less, and bounded as follows: on the southeast by De Touraine Street, on the northeast by a part of lot 204, on the southwest by a part of lot 205 and on the northwest by a part of lots lliO and 122.Cadastre de la paroisse de Sainte-Famille de Boucherville (suite) Cadastre of the parish of Sainte-Famille de Boucherville (continued) Rôle Roll Nom du propriétaire Name of proprietor Description de l'immeuble Description of immovable 2-70-051 Evdo Construction.Une partie du lot 204 bornée comme suit: au nord-ouest par la rue De Touraine, au sud-est par la Route Trans-Canadienne, ou nord-est par une partie du lot 202 et au sud-ouest par une partie du lot 205.3-85-451 | Mavien, S.A.Une partie du lot originaire 213 mesurant 700 pieds dans la ligne ouest, 4,485 pieds dans une ligne nord-est, 33 pieds dans une ligne est, 150 pieds duns une autre ligne nord-est, 522 pieds dans une autre ligne est, 4,491 pieds duns la ligne sud-ouest, et bornée comme suit : ft l'ouest par le chemin du cinquième rang, au nord-est par une partie du lot 212, à l'est et au nord-est par une partie du lot 213 (réserve), de nouveau ft l'est pur le chemin de la Savane, et au sud-ouest pur le lot 214.(Superficie 50.300 urpents carrés), mesures françaises.A part of lot 204 bounded as follows: on the northwest by De Touraine Street, on the southeast by Trans-Canada Highway, on the northeast by u part of lot 202 and on the southwest by a part of lot 205.2-79-051 I Evdo Construction.Une partie du lot 204 bornée comme suit: au sud-est pur une purtie du lot 204 et la rue De Lorraine, au sud-ouest pur une partie du lot 205 et uu nord-ouest par la route Trans-Canadienne.A part of the original lot number two hundred anil thirteen (213 Ft.) on the official plan and book of reference of the parish of Ste-Familie de Boucherville, measuring the suid part seven hundred and six feet (700') in its westerly line, four thousand four hundred and eighty-five feet (4,485') in a northeasterly line, thirty-three feet (33') in an easterly line, one hundred und fifty feet (160') in an other northeasterly line, live hundred and twenty-two feet (522') in an other easterly line, four thousand four hundred and ninety-one feet (4,491') in the southwesterly line and bounded as follows: to the west by the road of fifth range, to the northeast by a part of lot 212, to the east and to the northeast by a part of lot 2l3 (reserve), to the cast again by the road (Savane) and to the southwest by the lot 214 (Superficial area of 60,300 square arpents); French measures.A part of lot 204 bounded as follows: on the southeast by a part of lot 204 und De Lorraine Street, on the southwest by u part of lot 205 and on the northwest by Trans-Canada Highway.2-51-G75 Cadieux, Paul Aimé.29 112.Cadastre du Village incorporé \u2014 Cadastre of the Village incorporated 2-41-573 2-41-575 Lnnglois, Philippe Mme-Mrs.et-and Yves, Serge, Jean-Pierre, Régent, Gilles, Marcel, Suzunne et-and Claire Langlois.Langlois, Philippo Mine-Mrs.et-and Yves, Serge, Jean-Pierre, Régent, Gilles, Marcel, Suzanne et-and Claire Langlois.07.08.Donné à la ville de Boucherville, ce 2e jour de décembre 1969.(Sceau) Le greffier, 32252-50-2-o Eugène McClisii.Given at the town of Boucherville, this 2nd day of December, 1969.(Seal) Eugène McClisii, 32252-50-2-o City Clerk.Sièges sociaux B.R.C.E.inc.Avis est donné que la compagnie « B.R.C.E.inc.» a changé son siège social du numéro 676, avenue Outremont, Outremont, au numéro 3801, boulevard Industriel est, Montréal-Nord.Le secrétaire, Jacques Vallée.32295-0 2831-68 Head Offices B.R.C.E.inc.Notice is hereby given that \"B.R.C.E.inc.\" has changed its head office from 676 Outremont Avenue, Outremont, to 3801 Industrial Boulevard East, Montreal North.Jacques Vallée, Secretarii.32295 2831-68 F.L.Beique Inc.Avis est donné que la compagnie « F.L.Beique Inc.\", a changé son siège social du numéro 9135, boulevard LaSalle, LaSalle à Saint-Laurent.Le secrétaire, Jacques Beique.32296-0 1325-31 F.L.Beique Inc.Notice is hereby given that \"F.L.Beique Inc.\", has changed its head office from 9135 LaSalle Boulevard, LaSalle to Saint-Laurent.Jacques Beique, Secretary.32296 1325-31 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December SO, 1969, Vol.101, No.51 7063 Agence Publigraphic inc Publigraphic Agency Inc.Avis est donné que la compagnie « Agence Publigraphic inc.\u2014 Publigraphic Agency Inc.», constituée en corporation par lettres patentes datées du 18 octobre 1966, et ayant son siège social dans Montréal, où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui à 4224, rue St-Hubert, l'a transporté a 16, Elgin, Mart E, Place Bona-ventiire.Le président, Maurice Renaud.32292-0 4188-66 Ameublement D.C.Télévision inc.Avis est donné que la compagnie « Ameublement D.C.Télévision inc.», constituée en corporation par lettres patentes datées du 14e jour d'avril 1969 et ayant son siège social à Ville St-Picrrc, a établi son bureau ù 330, rue St-Jacques.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Le secrétaire, Gérard Noël.322(13-0 1659-69 Avec inc.Avis est donné que la compagnie « Avec inc.», constituée en corporation par lettres patentes, en date du 6 mai 1969, et ayant son bureau principal au no 2010 rue Clossc, app.2, à Montréal, l'a transporté, de ladite adresse, au no 362, rue Lubadie, Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie, comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 8e jour de mai 1969.Le secrétaire, Marie Paule Poirier.32294-0 1938-69 Itouchcrie Idéale (Baie-Comcau) inc.Avis est donné que la compagnie « Boucherie Idéale (Baie Comcau) inc.», constituée en corporation sous la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes émises par le lieutenant-gouverneur dc la province de Québec, en date du 29 mai 1969, et ayant son siège social à liaic-Comeau, a établi son bureau au numéro 7(i._itvenuc Louis-Philippe Gagné.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme éliml son siège social.Daté à Baie-Comeau, ce 25e jour de novembre 1969.Le président, Gilles Périgny.32297-0 2605-69 Gilbert & Gilbert limitée Avis est donné que la compagnie « Gilbert & Gilbert limitée», constituée en corporation par lellres patentes datées du 10 décembre 1958, et ayant son siège social à Québec, où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui à 376, rue des h renés ouest, l'a transporté à 241, rue des Saules ouest.Québec, ce 20 novembre 1969.Le président, Edgar Gilbert.\u2022^2A9-o 14315-58 Agence Publigraphic inc Publigraphic Agency Inc.Notice is hereby given that \"Agence Publigraphic inc.\u2014 Publigraphic Agency Inc.\", incorporated by letters patent dated October 18, 1966, and having its head office in Montreal, where it had its office until today at 4224 St-Hubert, Street, has transferred it to 16 Elgin, Mart E, Place Bonaventure.32292 Maurice Renaud, President.4188-66 Ameublement D.C.Télévision inc.Notice is given that \"Ameublement D.C.Télévision inc.\", incorporated by letters patent dated the 14th day of April, 1969, and having its head office in Ville St-Pierre, has established its office at 330 St-Jacques St.From and after the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Gérard Noël Secretary.32293 1659-69 Avec inc.Notice is hereby given that \"Avec inc.\", incorporated by letters patent dated May 6, 1969, and having its head office at 2010 Clossc Street, Apt.2, at Montreal, has transferred it from the said address to 362 Labadie Street, Montreal.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being the head office.Given at Montreal, this 8th day of May, 1969.Marie Paule Poirier, Secretary.32294 1938-69 Boucherie Idéale (Baie-Comeau) inc.Notice is hereby given that the company \"Boucherie Idéale (Baie-Comeau) inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patent, bearing date on May 29, 1969, issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Québec, and having its head office in Baie-Comeau, has established its office at number 76 Louis-Philippe Gagné Avenue.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Baie-Comeau, this 25th day of November, 1969.Gilles Périgny, President.32297-o 2605-69 Gilbert & Gilbert limitée Notice is hereby given that the company \"Gilbert & Gilbert limitée\", incorporated by letters patent dated December 10, 1958, and having its head office in Québec, where its office in Québec, where its office was situated up to to-day at 376 des Frênes West, has moved it to 241 des Saules West.Québec, on November 20, 1969.Edgar Gilbert, President.32299-0 14315-58 7064 GAZKTTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 décembre 1969, 101' année, »° 61 Foyer Sacré-Coeur de Berthicrville inc.Avis est donné que lu corporation « Foyer Sacré-Coeur de Itcrthiervillc inc.», constituée en corporation en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies par lettres patentes émises le 24 juillet 1969 et ayant son siège social à Itcrthiervillc, a établi son bureau du numéro 1010, rue Montcalm.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la corporation comme étant son siège social.Donné à lterlhierville, le 2 octobre 1969.La présidente.Soeur Claire Barrette.32208-o 2299-69 Boss E.Haydcn Sales Inc.Avis est donné que « Ross E.Hayden Sales Inc.», a transporté son siège social de 450 nord, avenue Wolsclcy, Montréal-ouest, à 428, avenue lteechwood, Rosemère.Le secrétaire, Mme Sandra-Lee Hayden.32300 3730-66 Les Placements Langlois ltée Langlois Holdings Ltd.Avis est donné que la compagnie « Les Placements Langlois ltée \u2014 Langlois Holdings Ltd.», constituée en corporation par lettres patentes en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, en date du 25 septembre 1969, et ayant son siège social en la cité dc Montréal, a établi son bureau au numéro 8897, dc la rue Chateaubriand.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné ù Montréal, ce 20e jour dc novembre 1969.Le président, Denis Langlois.32301-o 3917-69 North End Paradise Development Corp.Avis est par les présentes donné que « North End Paradise Development Corp.», une corporation constituée par lettres patentes en date du 10 septembre 1957, et ayant son siège social ù Montréal, où jusqu'à ce jour, son bureau était situé à 445 ouest, Jean-Talon, l'a transporté ù 10670, rue St-Hubert.Le secrétaire, Leah Kotler.32302 12896-57 Placements Charlcsbourg, limitée Avis est donné que lu compagnie « Placements Charlesbourg, limitée », a changé son siège social du numéro 215, 75c Rue est, Charlesbourg, au numéro 901, avenue Cardinal-Rouleau, Québec.Le président, Bernard Grenier.32303-o 12179-59 Cogena inc.Avis est donné que « Cogena inc.», incorporée par lettres patentes en date du 24 octobre 1967, a changé son siège social de 8585, boul.Saint-Laurent, Montréal, à 110 ouest, boul.Crémazie, suite 1450.Le 12 novembre 1969.Le secrétaire-adjoint, Michèle Saint-Jean.32355-0 4444-67 Foyer Sacré-Coeur de Berthicrville Inc.Notice is hereby given that \"Foyer Sacré-( locur de Berthicrville inc.\", incorporated by letters letters patent dated July 24, 1969, issued under Part III of the Companies Act, and having its head office in Berthicrville, has established its office at 1010 rue Montcalm.From and after the date of this notice, the suid office shall be considered by the company as being the head office of the corporation.Dated at Berthicrville, October 2, 1969.Soeur Claire Barrette, Président.32298-o 229'.)-0!l Ross E.Iluydcn Sales Inc.Notice is given that \"Ross E.Hayden Sales Inc.\", has transferred its head office from 459 Wolseley Avenue North, Montreal West to 12s lteechwood Avenue, Rosemère.Mrs.Sandra-Lee Hatden, Secretary.32300-o 3730-06 Les Placements Langlois Itce Langlois Holdings Ltd.Notice is hereby given that \"Les Placements Langlois ltée \u2014 Langlois Holdings Ltd.\", company incorporated by virtue of letters patent under the Part I of the Companies Act.on September 25, 1969, and having its head ollicc in the city of Montreal, has established its ollicc at number 8897 Chateaubriand Street.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as licing the head office of the company.Given at Montreal, this 20th day of November.1969.Denis Langlois, President.32301-o 3917-11!) North End Paradise Development Corp.Notice is hereby given that the company \"North End Paradise Development Corp.\", company incorporated by letters patent dated September 10, 1957, and having its head ollicc in Montreal, where its office was situated up to to-dav, at 445 Jean Talon West, has moved it lo 10670 St.Hul>ert Street.Leah Kotler.Secretary.32302-o 12896 57 Placements Charlesbourg, limitée Notice is given that \"Placements Charlcsbourg, limitée\", has transferred its head ollicc from 215.75th Street East, Charlesbourg lo 901 Cardinal-Rouleau Avenue, Québec.Bernard Grenier.Présidai1.32303-o 12179-59 Cogena inc.Notice is given that \"Cogena inc.\", incorporated by letters patent dated October 24, 1967.has changed its head office from 8585 St.Lui'\" ni Blvd., Montreal lo 110 Cremazie Blvd., West, suite 1450.November 12, 1909.Michèle Saint-Jean, Assistant Secretary.32355-0 4441-67 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December SO, 1969, Vol.101, No.51 7065 Coperna inc.Avis est donné que « Coperna inc.», incorporée par lettres patentes en date du 28 août 1968, a change son siège social de 8585, boul.Saint-l.aurenl, Montréal, Québec, à 110 ouest, boul.Créinazie, suite 1450,Montréal 351, Québec.l,e 12 novembre 1969.Le secrétaire-adjoint, Michèle Saint-Jean.32356-0 3911-68 Coperna inc.Notice is given that \"Coperna inc.\", incorporated by letters patent dated August 28,1968, has changed its head office from 8585 St.Laurent Blvd., Montreal to 110 Cremazie Blvd.West, suite 1450, Montreal 351, Québec.November 12, 1969.Michèle Saint-Jean, Assistant Secretary.32356-0 3911-68 Fcrïne La Cravache inc.Avis est donné que la compagnie « Ferme La Cravache inc.», a changé son siège social de Saint-Augustin, au numéro 2520, rue Beaubien est.Montréal.Le secrétaire, Leopold Denault.32357-0 4911-66 Ferme La Cravache inc.Notice is given that \"Ferme La Cravache inc.\", bas changed its head office from Saint-Augustin, to number 2520 Beaubien Street East, Montreal.32357 Leopold Denault, Secretary.4911-66 Habitat Matane Inc.Avis est donné que la compagnie « Habitat Matane Inc.», constituée en corporation en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, par lettres patentes émises le 23 septembre 1969 et ayant son bureau principal dans la ville de Matanc, province de Québec, a établi son bureau au numéro 119, rue St-Pierre.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné ù Matanc, ce 25e jour de novembre 1909.Le président, Bertrand Rioux.32358-0 4590-69 Habitat Matane Inc.Notice is given that \"Habitat Matane Inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act issued by letters patent on September 23, 1969, and having its head office in the town of Matane, Province of Québec, as established its office at number 119 St-Pierre St.From and after the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Matane, this 25th day of November, 1969.Bertrand Rioux, President.32358 4590-69 La Malbaie Auto Parts Inc.Avis est donné que la compagnie « La Malbaie Auto Parts Inc.», constituée en corporation dans la province de Québec, par lettres patentes accordées en vertu des dispositions dc la première partie de la Loi des compagnies, en date du 12 septembre 1969, et ayant son bureau principal ù La Malbaie, district dc Saguenay, Province de Québec, a établi son bureau au numéro 92, me St-Étienne.A compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Signé à Québec, ce 27c jour de novembre 1969; Le président, Roméo Boucher.32359«i 4372-69 La Malbaie Auto Parts Inc.Notice is hereby given that \"La Malbaie Auto Parts Inc.\", incorporated in the Province of Québec, by letters patent granted pursuant to the Provisions of Part I of the Companies Act, dated September 12, 1969, and having its head office in the city of La Malbaie, district of Saguenay, Province of Québec, has established its office at 92 St.Etienne Street.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Signed at Québec, this 27th day of November, 1969.Roméo Boucher, President.32359-0 4372-69 O'Sullivan Business College Inc.Avis est donné que la compagnie, « O'Sullivan business College Inc.», constituée en corpora-tion par lettres patentes, en date du 28 avril 1949, et ayant son siège social dans Montréal, où elle avant son siège social situé jusqu'aujourd'hui nu numéro 2059, de la rue Stanley, l'a transporté ail numéro 1191, de la rue de la Montagne.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.19t?0nn^ ntr^' ce *k i°ur ^e novembre (Sceau) Le secrétaire, Monique Bachand Rousseau.¦I2:ï00-o 2395-49 O'Sullivan Business College Inc.Notice is hereby given that \"O'Sullivan Business College Inc.\", company incorporated by letters patent, on April 28, 1949, and having its head office in the city of Montreal, where its office was situated up to today, at 2059 Stanley Street, in the city of Montreal, has moved it to 1191 de la Montagne Street.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Given at Montreal, this 3rd day of November 1969.(Seal) Monique Bachand Rousseau, Secretary.32360-o 2395-49 7006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SO décembre 1969, 101' année, «\u2022 51 Paramount Specialties Ltd.Avis est donné que la compagnie « Paramount Specialties Ltd.» a changé son siège social du numéro 460, rue St-Jacqucs, Saint-Pierre, au numéro 29, St-Joscph, Lachinc.Le président, Gilles P.Voizahd.32301-o 502-68 Neville Salmon & Associates Ltd.Avis est donné que < Neville Salmon & Associates Ltd.» a transporté son siège social de 485, rue McGill, bureau 306, Montréal, à 772, avenue Halpcrn, Dorval.Ia: secrétaire-trésorier, lloukut McCULLOUGH.32862 4198-67 Semitic inc.Avis est donné que la compagnie « Seminc inc.», a changé son siège social du numéro 1, Place Lavai, Laval, au numéro 2647, rue Allard, suite 5, Montréal.ht président, Claude Chartrand.32363-o 10536-62 Rusty Staub Inc.Avis est donné que la compagnie « Rusty Staub Inc.», a changé son siège social de Lachinc au bureau 1011, 3, Carré Westmount, Westmount.Ia: secrétaire, M.P.Maloney.32364 4135-69 Paramount Specialties Ltd.Notice is given that \"Paramount Specialties Ltd.\", has changed its head office from number 360 St.James Street, Saint-Pierre, to number 29 St.Joseph, Lachine.Gilles P.Voizaiiii, 32361 President.502-08 Neville Salmon & Associates Ltd.Notice is given that \"Neville Salmon & Associates Ltd.\", has transferred its head ollicc from 485 McGill Street, Suite 300, Montreal to 772 Halpern Avenue, Dorval.Robert McCullougii.Secretary-Trcas tirer.32362-o 4198-67 Semitic inc.Notice is given that \"Seminc inc.\", has transferred its head office from number 1 Laval Place.Laval, to number 2647 Allard Street, Suite 5, Montreal.Claude Chartbanu, President.32363 10536-62 Rusty Staub Inc.Notice is given that \"Rusty Staub Inc.\", has transferred its head office from Lachinc to Suite 1011, 3 Westmount Square, Westmount.32304-o M.P.Maloney, Secretary.4135-69 Bills \u2014 Assemblée nationale Bills \u2014 National Assembly Cabinet du Lieutenant-gouverneur Office of the Lieutenant-Goveunoii Quebec, IS décembre 1969.Aujourd'hui, ù quatre heures et demie de l'après-midi, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les bills suivants: 10 Loi concernant les régimes matrimoniaux.26 Loi de l'aide sociale.71 Charte du Centre de recherche industrielle du Québec.72 Loi modifiant dc nouveau la Loi des tribunaux judiciaires.74 Loi modifiant de nouveau le Code de procédure civile.78 Loi de la conservation de ln faune.79 Loi modifiant la Loi «les décrets dc convention collective.S0 lx>i modifiant la Loi des accidents du travail.82 Ixii modifiant la Loi dc l'impAt sur les corporations.Québec, lSth of December 1060.This day, at half past four o'clock in Ihr afternoon, the Honourable the Lieutenant-Governor was pleased to sanction the following hills: 10 An Act respecting matrimonial regime-.26 Social Aid Act.71 Charter of the Centre de recherche industrielle du Québec.72 An Act to again amend the Courts of Justice Act.74 An Act to again amend the Code of Civil Procedure.78 Wild-life Conservation Act.79 An Act to amend the Collective Agreement Decrees Act.80 An Act to amend the Workmen's Compensation Act.82 An Act to amend the Corporation Tax Act QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1969, Vol.101, No.51 7067 S3 Loi concernant le registre central des régimes matrimoniaux.84 Loi modifiant de nouveau la Loi dc la Régie des alcools.S.ï Loi prolongeant la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires.87 Loi du ministère des communications.88 Loi abrogeant la Loi du secrétariat et modifiant d'autres dispositions législatives.ml Loi modifiant la Loi des infirmières.1)4 Loi modifiant la charte du Bromc-Missisquoi-l'erkins Hospital.!);'> Loi concernant un immeuble situé dans la municipalité de la paroisse de Saint-Am-broisc-de-Kildare.flli Loi concernant un immeuble situé dans la municipalité de la paroisse dc Saint-Esprit.101 Loi concernant La Fabrique de la paroisse tic Sainte-Cécile de Salabcrry-de-Valleyfield.237 Loi concernant Valleyfield Golf and Country Club Inc.La sanction royale est prononcée sur ces bills |)iir le secrétaire de la chancellerie, comme suit: « Au nom dc Sa Majesté, l'honorable licutc-iiaiil-gouverneur sanctionne ces bills.» 32373-0 83 An Act respecting the central register of matrimonial regimes.84 An Act to again amend the Liquor Board Act.85 An Act to prolong the Act to promote conciliation between lessees and property-owners.87 Communications Department Act.88 An Act to repeal the Provincial Secretary's Department Act and to amend other legislative provisions.89 An Act to amend the Nurses Act.94 An Act to amend the charter of the Bromc-Missisquoi-Pcrkins Hospital.95 An Act respecting an immoveable situated in the municipality of the parish of Saint-Ambroise-de-Kildare.96 An act respecting an immoveable situated in the municipality of the parish of Saint-Esprit.104 An Act respecting The Fabrique of the parish of Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield.237 An Act respecting Valleyfield Golf and Country Club Inc.To these bills the Royal assent was pronounced by the Secretary of the Crown in Chancery in the following words: \"In Her Majesty's name, the Honourable the Lieutenant-Governor assents to these bills.\" 32373-o Divers Compagnies Miscellaneous Companies La Bibliothèque de l'uni ha m inc.The Farnham Public Library Inc.Avis est donné que le secretaire de la province a, le 24 septembre 1969, approuvé les amendements aux règlements généraux de la corporation « La Bibliothèque de Farnham inc.\u2014 The Farn-liniu Public Library Inc.».et ce, en vertu dc l'article S de la Loi des clubs dc récréation et dc l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douvii.le.323004 274-58 La Bibliothèque dc Farnham inc.The Farnham Public Library Inc.Notice is hereby given that the Provincial Secretary, on September 24, 1969, approved the amendments to the general by-laws of \"La Bibliothèque de Farnham inc.\u2014 The Farnham Public Library Inc.\", and such, pursuant to section 8 of the Amusement Clubs Act and to section 225 of the Companies Act.Raymond Doivii.le, Assistant Secretary of the Province.32306 274-58 Continental Adjustment Bureau Limited Continental Adjustment Bureau Limited Avis est par les présentes donné que la compagnie « Continental Adjustment Bureau Limited a changé le nombre de ses administrateurs de 5 ù 3.Le secrétaire, Lou Abbams.32309 13903-57 Distribuco inc.Avis est donné que la compagnie « Distribuco \"ic .a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le président, Rocii Bellemahe.32312-0 3965-67 Notice is given that \"Continental Adjustment Bureau Limited\", has changed the number of its directors from 5 to 3.32309-o LOU AuilAMS, Secretary.13903-57 Distribuco inc.Notice is hereby given that \"Distribuco inc.\", has changed the number of its directors from 3 to 4.Rocn Bellemare, President.32312 3965-67 7068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 décembre 1969, 101' année, n\" 61 Camp Richelieu St-Clémcnl inc.Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a, le 2 décembre 1969, approuvé les règlements généraux de la corporation < Camp Richelieu St-Clément inc.», et ce, en vertu dc l'article 225 dc la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32307-o 2080-69 Centre Social Louis Braille inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 3 dc la corporation « Centre Social Louis Braille dc Québec », constituée par lettres patentes en date du 22e jour dc juillet 1949, changeant son nom en celui dc « Centre Social Louis Braille inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32308-o 6010-49 Camp Richelieu St-Clémcnt inc.Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on December 2, 1969, approved the general by-laws of \"Camp Richelieu St-Clcmcnl inc.\", and such, pursuant to section 225 of Ha Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32307 2080-6fJ Centre Social Louis Braille inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives lias approved the by-law number 3 of the corporation \"Centre Social Louis Braille de Québec\", incorporated by letters patent dated the 22nd day of July, 1969, changing ils name into that of \"Centre Social Louis Braille inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32308-o OOKl-l!) Cordon Bleu Limited Cordon Bleu (limitée) Avis est donné que la compagnie « Cordon Bleu Limited \u2014 Cordon Bleu (limitée)», a changé le nombre dc ses administrateurs dc 5 à 3.Le secrétaire-trésorier, Raymond Robert.32310-o 5932-39 Cuir 21 ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 59, de la compagnie « Cuir 20 ans ltée », constituée par lettres patentes en date du 29c jour d'août 1969, changeant son nom en celui de « Cuir 21 ltée ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32311-o 4280-69 Cordon Bleu Limited Cordon Bleu (limitée) Notice is given that \"Cordon Bleu Limited Cordon Bleu (limitée)\", has changed the number of its directors from 5 to 3.32310 Raymond Robert, Secretary-Treasurer.5932-3!) Cuir 21 ltée Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law number 59, of the company \"Cuir 20 ans ltée\", incorporated by Idlers patend dated the 29th day of August, 1909, changing its name into that of \"Cuir 21 ltée\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ire.32311-0 4280-68 Dominion Textile Investments Limited Avis est donné que « Dominion Textile Investments Limited », a changé le nombre dc ses administrateurs de 5 à 4.Le secrétaire, C.M.Beck.32313 3146-64 Dominion Textile Investments Limited Notice is given that \"Dominion Textile In vestments Limited\", has changed the number of ils directors from 5 to 4.C.M.Beck.Secretary.32313-o 3146-61 Les Immeubles Bocage inc.Avis est donné que la compagnie « Les Immeubles Bocage inc.», a changé le nombre dc cos administrateurs de 3 a 4.Le secrétaire, Hugues Ferron.32314-q 3913-69 Les Immeubles Bocage inc.Notice is hereby given that \"Les Immeubles Bocage inc.\", has changed the number of its directors from 3 to 4.Hugues Ferron, Secretary.32314 3913-00 Lab-Volt (Oucbcc) Limited Lab-Volt (Québec) limitée Avis est donné que « Lab-Volt (Québec) Limited\u2014 Lab-Volt (Québec) limitée», a changé le nombre de ses administrateurs de 7 à 3.Le secrétaire, John E.Lawrence.32315 13075-59 Lab-Volt (Québec) Limited Lab-Volt (Québec) limitée Notice is given that \"Lab-Volt (Québec) I i niitcd \u2014 Lab-Volt (Québec) limitée\", has changed the number of its directors from 7 to 3.John E.Lawrence, Secretary, 32315-0 13075-511 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1969, Vol.101, No.51 7069 Allstate Enterprises, Inc.Armour Pharmaceutical Company Canmont Mining Properties Limited llo» Corning Silicones Inter-America Ltd.Eastern Specialties Corp.I''.:islman Chemical Inter-American Ltd.Eaton Yale & Townc Inc.Frccport Canadian Exploration Company Frceport Sulphur Company C.W.Fuelling, Inc.Hotel Corporation of America (Manitoba) Ltd.Jolis I Institute, Inc.Kerr-McGce Corporation Leonard Construction Company George Lucdcrs & Co., Incorporated Marathon Oil Company Mohawk Airlines, Inc.Ohio Oil Company Pcnnzoil United, Inc.Safely Electrical Equipment Corp.Plymouth Golf Ball Sales Company Procon Incorporated Richardson-Mcrrell Inc.Service Review, Inc.Solo Cup Company Thermo King Corporation Travelodge Ltd.United States Steel International, Ltd.Avis est donné que, par nouvelle procuration, « C T Corporation System (Canada) Ltd », a etc nommé agent principal en cette province de chacune des compagnies étnngères ci-haut mentionnées, aux lieu et place dc Me André Desjar-dins et que le bureau principal dans cette province dc chacune des compagnies ci-haut mentionnées, a été transporté au bureau dudit agent principal, 55 rue d'Auteuil, Québec.Québec, le 6 novembre 1969.Le procureur des compagnies, Michael Sheehan, avocat.18-02 Allstate Enterprises, Inc.22-62 Armour Pharmaceutical Company 60-68 Canmont Mining Properties Limited 70-67 Dow Corning Silicones Intcr-Ameriea Ltd.ôli-68 Eastern Specialties Corp.50-02 Eastern Chemical Inter-American Ltd.23-69 Eaton Yale & Townc Inc.20-65 Frccport Canadian Exploration Company 16-64 Frccport Sulphur Company \u2022100-59 C.W.Fuelling, Inc.30-68 Hôtel Corporation of America ( Manitoba) 1-68 Jobst Institute, Inc.7-66 Kcrr-McGec Corporation 417-56 Leonard Construction Company 20-68 George Lueders & Co., Incorporated 43-62 Marathon Oil Company 27-67 Mohawk Airlines, Inc.16-61 Ohio Oil Company 32-68 .Pcnnzoil United, Inc.-*\u2014-'> 1 Safety Electrical Equipment Corp.14-09 Plymouth Golf Ball Sales Company 33-68 Procon Incorporated 796-60 Richardson-Mcrrell Inc.3-66 Service Review, Inc.570-60 Solo Cup Company 45-62 Thermo King Corporation 33-62 Travelodge Ltd.53-64 United States Steel International, Ltd.32291-6 Allstate Enterprises, Inc.Armour Pharmaceutical Company Canmont Mining Properties Limited Dow Corning Silicones Inter-America Ltd.Eastern Specialties Corp.Eastman Chemical In ter-American Ltd.Eaton Yale & Townc Inc.Frceport Canadian Exploration Company Frceport Sulphur Company C.W.Fuelling, Inc.Hotel Corporation of America (Manitoba) Ltd.Jobst Institute, Inc.Kerr-McGce Corporation Leonard Construction Company.George Lueders & Co., Incorporated Marathon Oil Company Mohawk Airlines, Inc.Ohio Oil Company Pennzoil United, Inc.Safety Electrical Equipment Corp.Plymouth Golf Ball Sales Company Procon Incorporated Richardson-Merrcll Inc.Service Review, Inc.Solo Cup Company Thermo King Corporation Travelodge Ltd.United States Steel International, Ltd.Notice is given that by new powers of attorney \"C T Corporation System (Canada) Ltd\", has been appointed chief agent in this province of each of the above mentioned extra-provincial companies, in the place and stead of André Desjardins, and that the principal office in the province of each of the above mentioned companies has been moved to the office of the suid chief agent, 55 d'Auteuil, Québec.Québec, November 6, 1969.Michael Sheehax, udvocate.Attorney of the companies.Ltd.3229l-o 7070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 décembre 1969, 101' année, n\" 51 Sauna Frontenac inc.Avis est donné que la compagnie « Sauna Frontenac inc.», a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 5.Le secrétaire, Roger Matte.32316-o 2648-67 L'Alliance des Associations Hongroises de Montréal The Alliance of Hungarian Associations of Montreal Avis est donné que la corporation « L'Alliance des Associations Hongroises de Montréal \u2014 The Alliance of Hungarian Associations of Montreal », a changé le nombre de ses administrateurs dc 6 à 12.Le président, Akos de S.Muszka.32347-0 4319-69 Sauna Frontenac inc.Notice is given that \"Sauna Frontenac inc.\", has changed the number of its directors from 4 to 5.Roger Matte, Secretary.32316 2648-67 L'Alliance des Associations Hongroises de Montréal The Alliance of Hungarian Associations of Montreal Notice is given that \"L'Alliance des Associations Hongroises de Montréal \u2014 The Alliance of Hungarian Associations of Montreal\", has changed the number of its directors from 6 to |2.Akos de S.Muszka.President.32347 4319-69 L'Alliance des Associations Hongroises de Montréal The Alliance of Hungarian Associations of Montreal Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a, le 4 décembre 1969, approuvé les règlements généraux de la corporation « L'Alliance des Associations Hongroises de Montréal \u2014 The Alliance of Hungarian Associations of Montreal », et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutio?is financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32347-o 4319-69 L'Alliance des Associations Hongroises dc Montréal The Alliance of Hungarian Associations of Montreal Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, on December 4, 1969, approved the general by-laws of \"L'Alliance des Associations Hongroises de Montréal \u2014 The Alliance of Hungarian Associations of Montreal\", and such, pursuanl lo section 225 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32347 4319-69 College Laval dc St-Vincent de Paul Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a, le 3 décembre 1969, approuvé le règlement spécial «A » 1969, de la corporation « Collège Laval de St-Vincent de Paul », et ce, en vertu dc l'article 226 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32348-o 11083-59 Collège Laval de St-Vincent de Paul Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on December 3, 1969, approved special by-law \"A\" 1969, of \"Collège Laval de St-Vincent de Paul\", and such, pursuant to section 226 of I he Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Coopcratires.32348 U0S3-59 Continental Plumbing & Heating Inc.Avis est donné que la compagnie * Continental Plumbing & Heating Inc.», a changé le nombre dc ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire, Steven Resnick.32349-0 1280-67 Continental Plumbing & Heating Inc.Notice is given that \"Continental Plumbing & Heating Inc.\", has changed the number of ils directors from 4 to 3.Steven Resnick, Sccrelan,.32349-0 12S(iii7 Fondation Carol Brillant inc.Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a, le 2 décembre 1969, approuvé le règlement numéro 13 de la corporation « Fondation Carol Brillant inc.», et ce, en vertu dc l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, .Ls-Piulippe Bouchard.32350-o 3648-69 Fondation Carol Brillant inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has.on December 2,1969, approved by-law number 13 of \"Fondation Carol Brillant inc.\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperative.'.32350 361S-0» QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1969, Vol.101, No.51 7071 Nadco Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu du règlement numéro 23 dc < Nadco Investments Inc.», les liions dc la compagnie seront distribués entre ses actionnaires proportionnellement au montant d'actions qu'ils détiennent dc la compagnie, quinze (15) jours après la présente publication dudit avis.Les procureurs de la compagnie, 32351-0 Gorman, Marcovitch & Miller.Napiervillc Growers Inc.Avis est donné que « Napiervillc Growers Inc.», a changé le nombre dc ses administrateurs de 4 à 5.Le secrétaire, Robert Cobby.32352 699-08 Nadco Investments Inc.Notice is given that pursuant to by-law umber 23 of \"Nadco Investments Inc.\", the property of the company will be distributed among the shareholders in proportion to the amount of shares they hold fifteen (15) days after the present publication of the said notice.tii u.man, Marcovitch & Miller, 32351-o Attorneys for the company.Napiervillc Growers Inc.Notice is given that \"Napiervillc Growers Inc.\", has changed the number of its directors from 4 to 5.Robert Curry, Secretary.32352-0 699-68 Restaurant Le Petit Village Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 4, de la compagnie ¦ Au Petit Charles inc.», constituée par lettres patentes en date du 10c jour dc juillet 1969, changeant son nom en celui dc « Restaurant Le Petit Village».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32353-0 3453-69 Restaurant Le Petit Village Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law number 4, of the company \"Au Petit Charles inc.\", incorporated by letters patent dated the 10th day of July, 1909, changing its name into that of \"Restaurant Le Petit Village\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32353 3453-69 Sainthill-Levinc (Québec) Ltd.Avis est donné que « Sainthill-Lcvine (Québec) I.!'I.», a changé le nombre dc ses administrateurs de 4 à 7.Le secrétaire, Murray D.Levine.32354 18323-52 Suinthill-Lcvinc (Québec.) Ltd.Notice is given that \"Sainthill-Lcvine (Québec) LUI.\", has changed the number of its directors from 4 to 7.Murray D.Levine, Secretary.32354-0 18323-52 Nichimcii Co., Inc.Avis est par les présentes donné que, par une nouvelle procuration en date du 3 novembre 1969, dont une copie a été transmise au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, M.Hisatoshi Asakura, dc Montréal, a été nommé pour remplacer M.Yoshito Tsuji, agent principal duns la province, de « Nichimen Co., Inc.», une compagnie étrangère dûment autori-séc à exercer son commerce dans la province dc Québec, conformément aux dispositions dc la Loi des compagnies étrangères.Avis est aussi donné que conformément à la nouvelle procuration ci-dessus mentionnée, le bureau principal de ladite compagnie est établi à 1450, rue City Councillors, Montréal, district judiciaire de Montréal.Is sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Ls-Philippe Bouchard.32409 642-59 iSichinicii Co., Inc.Notice is hereby given that, by new power of attorney dated November 3, 1969, a copy of which was sent to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, Mr.Hisatoshi Asakura, of Montreal, was appointed to replace Mr.Yoshito Tsuji as chief agent in the Province of \"Nichimen Co., Inc.\", as Extra-Provincial Company duly authorized to carry on business in the Province of Québec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act.Notice is also given that pursuant to the above-mentioned new power of attorney, the head office of the said company is established at 1450 City Councillors Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Depidy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32409-o 042-59 Transport du Lac ltée Avis est donné que la compagnie * Transport du Lac ltée », a changé son siège social d'Alma û Bagotville.Le secrétaire, Jean-Marie Tremblay.32410-o 964-67 Transport du Lac ltée Notice is given that \"Transport du Lac ltée\", bas changed its bead office from Alma to Bagotville.Jean-Marie Tremblay, Secretary.32410 964-67 7072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 décembre 19G9, 101' aimée, n\" 51 Demandes à la Législature Alfred A.Baliary Avis est par les présentes donné que Alfred A.Baliary, domicilié au 5352, Bcssborough, en la cité dc Côtc-St-Luc, district dc Montréal, s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec, au cours de la prochaine session, pour obtenir l'adoption d'une loi autorisant le Barreau de la province de Québec à l'admettre à l'exercice de la profession d'avocat.Montreal, ce 26 novembre 1969.Les procureurs du requérant, Blain, Piché, Bergeron, Godbout, Emery, Blain & Vallerànd, avocats.32080-49-4-o The Syrian Greek Orthodox Church of St-Nicholns of Canada Avis est par les présentes donné «pic « The Syrian Greek Orthodox Church of St-Nicholas of Canada », s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec, ù sa prochaine session, pour demander l'adoption d'une loi aux fins dc changer son nom en celui dc «_St-Nicholas Antiochian Orthodox Church \u2014 L'Eglise orthodoxe St-Nicholas d'An-tiochc », et aux fins dc modifier ses pouvoirs.Montréal, ce 8c jour dc décembre 1969.Les procureurs des pétitionnaires, Bi.ain, Piché, Bergeron, Godboot, Emery 32335-51-2-0 Bi.ain & Vallerand.Applications to Legislature Alfred A.Baliary Notice is hereby given that Alfred A.Baliary, domiciled at 5352 Bessborough, in the city of Côte-St-Luc, district of Montreal, will apply to the National Assembly of Québec, during the next session, to request the adoption of an Act authorizing the Bar of the Province of Québec to admit Alfred A.Baliary to the practice of I lie legal profession.Montreal, this November 26, 1969.Blain, Piché, Bergeron, Godbout, Emery, Blain & Vallerand, advocates, Attorneys for the Petitioner.32080-49-4-o The Syrian Greek Orthodox Church of St-Nicholas of Canada Notice is hereby given that \"The Syrian (ireck Orthodox Church of St-Nicholas of Canada\", will apply to the National Assembly of Québec, at its next session, to seek the adoption of a Bill changing its name to \"St-Nicholns Antiochian Orthodox Church\u2014L'Eglise Orthodoxe St-Nicholas d'Antiochc\", and modifying its |K>wcrs.Montreal, December 8th, 1969.Bi.ain, Piché, Bergeron, Godbout, Emery, Blain & Vallerand, 32335-51-2-0 Solicitors for the Petitioners.Institutions financières, compagnies et coopératives Compagnies de fiiducie et de Jiinance Financial Institutions, Companies and Cooperatives Trust Companies National Trust Company, Limited Compagnie du Trust National Ltè\"c Avis de changement d'agent principal Avis est donné que « National Trust Company, Limited \u2014 Compagnie du Trust National Ltée », a désigné monsieur Gordon B.Empey, 1350 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, Québec, comme son agent principal au Québec, en remplacement de monsieur A.P.Smiberl.Le secrétaire, 32412-6 G.I).Forsyth.National Trust Company, Limited Compagnie du Trust National Ltée Solice of change of chief agent Notice is given that \"National Trust Company, Limited \u2014 Compagnie du Trust National Lice\", has appointed Mr.Gordon B.Empey, 1350, Sherbrooke St.West, Montréal, Québec, as ils chief agent for the province of Québec, succeeding to Mr.A.P.Smibcrt.G.D.Forsyth.32412-o Secretary.Compagnie autorisée Company Licensed à faire des affaires to do Business Gumhlcs Canada Limited Avis est pnr les présentes donné que le lie jour île novembre 1969, un nouveau permis a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, à « Gamble MacLeod Limited», l'autorisant à exercer son commerce en ladite province, sous son nouveau nom de \"(iambics Canada Limited », conformément aux dispositions de In Loi des compagnies étrangères, Statuts refondus, 1964, chapitre 2S2.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piii lippe Bouchard.32290 3-07\u2014 1520/110 Gambles Canada Limited Notice is hereby given that, on 11th day of November, 1969, a new license was granted by the Lieutenant-Governor of the Province of Québec lo \"Gamble MacLeod Limited'', authorizing it to carry on business in the said Province under its new name of \"Gambles Canada Limited\", pursuant to the provisions of the Exlra-Provincial Companies Act, Revised Statutes, 1964, chapter 2,S2.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32290-o 3-67 \u2014 1520/110 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December SO, 19G9, Vol.101, No.51 7073 Ministère de l'Industrie Department of Industry et du Commerce and Commerce Loi sur les pêcheries Règlement «le pèche rr Sinking Fund Debentures for Public Works, due February 1, 1991 » (ci-après appelées \u2022 Obligations ») «le la Ville dc Montréal, province ¦le Québec, Canada.AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNE que la Ville dc Montréal a l'intention de .acheter et rachètera POUR FINS D'AMOR-I1SSEMENT le 1er février 1970, conformément aux dispositions des obligations, les obligations suivantes (ou partie dc ces obligations) comme mentionné ci-après, de l'émission mentionnée \"-dessus, à 100% de leur montant en principal pus I intérêt couru à la date de rachat, à savoir: \u2022 uinéros des obligations entièrement immaculées portant le préfixe RE, rachctablcs le le- reyriçr 1970 jusqu'à concurrence du montant i» principal apiiaruissant vis-à-vis chacun des numéros suivants: Council Beaupré No.2896 of the Knights of Columbus of Beaupré Notice is hereby given that the Provincial Secretary has, on December 9, 1909, approved the general by-laws of \"Council Beaupré No.2896 of the Knights of Columbus of Beaupré\", and such, pursuant to section 9 of the Act respecting the Knights of Columbus of the Province of Québec nnd section 225 of the Companies Act.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.32329 1746-53 Corporation of Master Pipe Mechanics of Québec Notice is hereby given thut the amendment, the text of which is hereto annexed lo the regulations of the \"Corporation of Muster Pipe-Mechu-nics of Québec\", the head office of which is in the city of Quebec, will be submitted for npprovtil by the Lieutenant-Governor in Council, at the expiry of 30 days following the date of the publication of the present notice, the whole in conformity with the provisions of section No.10 of the Muster Pipe-Mechanics of Québec Act, R.S.Q., 1964, chapter 155.Section No.124 of the regulations of the Corporation is amended us follows: \"Change the words and figures one hundred (100) by the words and figures five hundred (500).\" Adrien Leuire, 32417 Executive Secretary.Estate of Arthur Girard Notice is hereby given that I, the undersigned.Marcel Girard, o|>crutor ut Hydro-Québec, residing at 2858 Sugucnuy Street, Norundu, Province of Québec, huvc accepted under benefit of inventory, the estate of Mr.Arthur Girard, while living automobile salesman, residing at 31 Pinder Street West, Rouyn, Province of Québec.This acceptance under beneficium inventorll was made by a deed duted November 12, I960, registered at Rouyn, on November 13, 1969, under number 14303, received before Me Gustave Tuschereiiu, notary, the study of whom is found ul 142 Principal Avenue.Rouyn, Province of Québec.32419 (Signed) Maiioel GlHAKD.City of Montreal Notice of Redemption To the holders of debentures payable in United States Currency of the issue designated \"5J^% Sinking Fund Debentures for Public Works, due February 1, 1991\" (herein called \"Debentures\") of the City of Montreal, Province of Québec, Canada.PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN that the City of Montreal intends to and will redeem for SINKING FUND PURPOSES on February 1, 1970, pursuant to the provisions of tho debentures, the following debentures (or portions thereof) us indicated, of the above-mentioned issue, at 100% of principal amount plus accrued interest to the redemption date, namely: Numbers of the Fully Registered Debentures bearing the prefix RE, redeemable on Februury February 1, 1970 to the extent of the principal amount shown against each of the following numbers: 7078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, £0 décembre 1969, 101' année, n° 61 RE5126.\t.$200,000\tRE5127.\t.$ 8,000 RE5130.\t.$ 3,000\tRE5131.\t.t 1,000 RE5136.\t.$ 10,000\tRE5137.\t.$ 40,000 RE5141.\t.$ 40,000\tRE5148.\t.$ 30,000 RE5153.\t.$ 4,000\tRE5154.\t.$ 4,000 RE5164.\t.$ 2,000\tRE5180.\t.$ 2,000 RE5214.\t.$ 20,000\tRE5216.\t.S 20,000 RE5219.\t.$ 16,000\tRE5221.\t.% 8,000 RE5224.\t.$ 6,000\tRE5225.\t.$ 6,000 RE5229.\t.$ 3,000\tRE5230.\t$ 2,000 RE5233.\t.$ 8,000\tRE5241.\t.$ 10,000 RE5248.\t.$ 12,000\tRE5252.\t.$ 10,000 Numéros des obligations à coupons: AUCUN NUMÉRO.Les obligations (ou partie de ces obligations) devant être ainsi rachetées, deviendront échues et payables et seront payées en telles espèces ou monnaie des États-Unis d'Amérique qui, au moment du paiement, aura cours légal pour le paiement des dettes publiques et privées dans lesdits ÉtaU-Unis d'Amérique, au bureau de Bank of Montreal Trust Company ou de The Royal Bank of Canada Trust Company, Borough of Manhattan, Cité et État de New-York, États-Unis d'Amérique, sur présentation et remise des obligations portant les numéros mentionnés ci-dessus, et dans le cas d'obligations à coupons, avec tous les coupons échéant après le 1er février 1970 attachés.Les obligations entièrement immatriculées et les obligations ù coupons immatriculées quant au principal doivent être accompagnées de procuration pour leur transfert dûment exécutée en blanc.Les obligations entièrement immatriculées représentant la partie non rachetée de toute obligation rachetée en partie seulement seront émises sans frais.Les obligations immatriculées seront immatriculées dc la même manière que les obligations remises à moins d'instructions «l'agir différemment.AVIS PUBLIC EST AUSSI PAR LES PRÉSENTES DONNÉ cru themselves accordingly. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1969, Vol.101, No.61 7101 Ex koi de Qtoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer |i' grand sceau île Notre province de Québec; témoin: Noire très fidèle et bien-uiiné l'honorable Hugues Lapointe, c.p., cit., lieutenant-gouverneur de Notre province dc Québec.Donné en Notre hotel du gouvernement, eu Nuire ville de Québec, de Notre province de Québec, ce dix-septième jour de décembre en l'année mil neuf cent soixante-neuf de l'ère chrétienne et de Notre Règne lu dix-huitième uiinéc.l'ar ordre.Le sou.i-secrétaire tic la proriitce, 32-17J-o Raymond Douville.rWncedç HUGUES LAPOINTE Québec.H- s.| ELIZABETH DEUX, pur la grâce .le Dieu Heine du Royaume-Uni, du Canada et dc ses autre royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur île la foi.À lous ceux (pii ces présentes lettres verront mi qu'icches pourront concerner, Salut.l'eue luillu i ion Le KMi.1-procureur C A TTENDU qu'en ver- ijiuirtil adjoint, ) **¦ tu du chapitre 1 des animé Desjardixs.| Statuts refondus de Qué-' bec, 1904, le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer pur proclamation tout jour comme jour dc fête publique; attendu qu'il est a propos dc déclarer jours fériés cl jours dc fêtes publiques les 26 décembre I960 el 2 janvier 1970.à nis causes, du consentement et île l'avis de Noire Conseil Exécutif, exprimés duns un décret |>ortnnt le numéro 4148, en date du 17 décembre 1969, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons que les 26 décembre 1969 et 2 janvier 1970 soient, jiour la province dc Québec, jours fériés et jours jours de fête publique.Dr.tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tout autres (pie les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et dc se conduire en conséquence.Ex koi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province dc Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., en., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville dc Québec, dc Notre province dc Québec, ce dix-huitième jour de décembre en I année mil neuf cent soixante-neuf dc l'ère chrétienne et de Notre Règne la dix-huitième année.Par ordre, Le sous-secrétaire de la province, 32372-ti Raymond Douville.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given at Our Parliament Buildings, in Our city of Québec, in Our Province of Québec, this seventeenth day of December, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and sixty-nine, and in the eighteenth year of Our Reign.By command, Raymond Douville, 32372 Assistant Secretary of the Province.Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELEZABETH THE SECOND, by the Grace of (Sod, of the United Kingdom, Canada and her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation André Desjardins,/ Ya/HEREAS pursuant Assistant-Deputy J to chapter 1 of the Attorney General.\\ Revised Statutes of Qué-\\ bee, 1964, the Lieutenant-Governor in Council may fix, by proclamation, any day as a public holiday; Whereas it is appropriate to declare December 26, 1969 and January 2,1970 as holidays and public holidays.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 4148, dated December 17, 1969, We have decreed and ordered, and, hereby decree and order that December 26, 1969 and January 2, 1970 be, in the Province of Québec, holidays and public holidays.Of all of which, Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice, and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, Wc caused these Our present letters to be made patent and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed: Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this eighteenth day of December in the year of Our Lord one thousand nine hundred and sixty-nine and in the eighteenth year of Our Reign.By command, Raymond Douville, 32372-0 Assistant Secretary of the Province. 7102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, -M décembre 1U00, 101e année, n' 51 ( unada.Province .le- HUGUES LAPOINTE Québec.IL.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Heine , Range 7 on the oflicial cadastre of the municipality of Enst Broughlon: 2.Loi 14b, Range 0 of thé oflicial cadastre of BasI Broughlon Station, with the buildings constructed ihereon, circumstances and dependencies.\" To be sold \"en bloc\" in the Registry Ollicc for I he division of Beauce, at Bcauceville-Kasl, county \u201ef Beauce, on the TWENTY-SEVENTH day of JANUARY, 1970, at TEN o'clock in the forenoon.Adalbert Lessard, Slwriff's Ollicc Deputy Sheriff.Town of St-Joscph dc Beauce, December 10, 19(59.32371 H E A DHARNOIS B E A U II A UNO IS De Terris District dc Bcauliaruois 1 ipéricurc, i T A SOCIÉTÉ CENTRANT 11,458.J-\" LE D'HYPOTHÉQUÉS l ET DE LOGEMENT, corps |Kiliiii|iic dû men I incorporé, d'un acte .lu gouvernerai ni Canadien, ayant son siège social dans la cité d'Ottawa, province d'Ontario cl une place ¦1 affaires en lu cité et district «le Montréal, demanderesse, ra JAMES E.TESSIER, domicilié - I Concordia, Chftteauguay, district «le Ilea nrnois, défendeur.I n emplacement faisant front sur la rue Concordia, dans la ville de Chftteauguay, P.Q.'\"nu,, i désigné et se composant des subdivisions ¦je i\"1 numéro deux cent quatre-vingt-dix-neuf \u2022lu loi originaire numéro quarante-huit (48-299) \u2022 t numéro quutrc cent soixante-treize du lot originaire numéro quarante-neuf (19-173) toutes ''eux lix plan et livre de renvoi officiels dc la paroisse dc Saint-Joachim de Chftteauguay, duns le comté île Chftteauguay, Québec, avec la maison qui y , -i érigée portant le numéro civique 311 «le ladite rue Concordia, membres et appartenances, ¦us1 xception ni réserve de lu part du vendeur.De Terris District of llcaiiliarnois Superior Court, fpHE CENTRAL MORT-N'o.11.45S.J- GAGE AND HOIS-l INC.CORPORATION, body politic duly incorporated, by a deed of the Canadian Government, having its head ollicc in the city of Ottawa, Province of Ontario, and a place of business in the city and district of Montreal, plaintiff, rs JAMES E.TESS 1ER, domiciled at 344 Concordia, Chûtcauguay, district of Bcauharnois, defendant.\"An emplacement fronting on Concordia Street, in the town of Chftteauguay, P.Q.known and designated and being composed of the subdivision lots number two hundred and ninety-nine of the original lot number forty-eight (4S-299) and of number four hundred and seventy-three of the original lot number forty-nine (49-473) ihiili on (he olliciul plan and book of reference of the parish of Saint Joachim de Chftteauguay, in the county of Chftteauguay, P.Q., with the house thereon erected and bearing civic number 344 of said Concordia Street, membersJand appurtenances, without exception nor reserve on the part 7104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 décembre 1969, 101' aimée, n° 51 Le tout tel qu'il est présentement avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou non apparentes qui y sont attachées.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division dc Chftteuuguuy à Ste-Martinc, le VINGT-DEUXIÈME jour dc JANVIER 1970, ù DIX heures dc Pavant-midi.Le shérif adjoint, Bureau du Shérif, J.Lucien Pmmeau.Suluberry dc Valleyfield, ce 10e jour dc décembre 1909.32375 KAMOURASKA Bref Venditioni Exponas dc Terris Canada \u2014 Province dc Québec District de Kamouraska Cour Provinciale( T ÊOPOLD RAYMOND, Kamouraska, J commerçant dc Notrc-N'o 2588.i Dame du Portage, deman-' «leur, m DION NE SPECIALTIES LTD., corporation légalement constituée ayant son siège d'affaires dans la ville dc Trois-l'islolcs, défenderesse.« Un terrain faisant partie îles lois Nos partie de 99 et partie de 117.au cadastre officiel de la paroisse dc Trois-l'istolcs, mesurant quatre cent quatre-vingt-cinq pieds (485') dc profondeur sur la lurgeur des lots 99 et 117; borné au nord-ouest pur une partie des lots 99 et 177 (succession J.-II.Rousseau) au nord-est pur le lot 98 (Martin & Martin Enrg.) au sud-est par le terrain du CNR, et uu sud-ouest par les lois 112 (CNR) et lu ville de Trois-l'istolcs, et purlic du lot cent vingt (120) ville de Trois-l'isloles, Georges D'Amours et J.-II.Duval Inc.; le tout avec bâtisses construites circonstances et dépendances; sujet à lu servitude ulfectunl les lois cent vingt et cent vingt et un (120 et 121).- Pour cire vendu uu burcuu d'enregsitreinenl, division de Témiscouata, uu Palais de Justice, .'13, rue «le lu Cour, Rivière-du-Loup, le TRENTIÈME jour dc JANVIER 1970, à DIX heures de Pavant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Maurice Morin.Rivièrc-du-I.oup, ce 12 décembre 1000.32370-o .M O N T M A G N Y Fieri Facias de Bonis et dc Terris Canada \u2014 Province de Québec District île Montmagny ( 'ou r Provinciale, t A RM AND CHABOT, for-Monlmagny, J geron, St-Fabien-de-No 2500.j l'aucl.comté dc Moiilinu-' gnv.demandeur, rs JACQUES MONTMIN Y, St - Pubien -i le- Pane t.comté de Montmagny.défendeur.« Une ferme sise et située en lu municipalité de St-Fabien-dc-Panct, comté dc Montmagny, formée de: n) l.e lot connu cl désigné sons le numéro dix (10) du rang cinq (Rg V) du cadastre officiel du canton Rolette: b) l'n terrain de lu contenance «le douse cents pieds (1200') en profondeur du nord-ouest uu sud-est par une largeur de huit cent cinquante pieds (850/) mesurée du nord-est au sud-ouest, soit lu lurgeur du loi.pris à même le lot connu cl désigné sous le numéro onze (Ptie 11) du of the vendor.As the whole now subsists with all the servitudes active or passive, apparent or unapparcnt thereto attached.\" To be sold at the registry office of the Chftteauguay division, at Sainte-Martine, on the TYYEN-TY-SECOND day of JANUARY, 1970, at TEN o'clock in the forenoon.J.Lucien Phimeai;, Sheriff's Oflicc, Associate Sheriff.Snlaberry de Valleyfield, this 10th day of December, 1909.32375.» KAMOURASKA Writ Venditioni Exponas de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Kamourasku Provincial Court/ T ÊOPOLD RAYMOND, Kamouraska, J tradcrof Notre-Dame du No.2588.\\ Portage, pluintiff, rs DION-{ NE SPECIALTIES LTD., u corporation legully incorporated having its head oflicc in the town of Trois-Pisloles, defendant.\"A piece of hind part of the lois of part Nos 99 and 117, on the official cadastre of the parish of Trois-Pisloles, measuring four hundred and eighty-five feel (485') in depth by the width of lots 99 and 117; hounded on the north-wcsl by a purl of lots 99 und 177 (J.-IL Rousseau Estate), on the north-cast by lot 9S (Martin & Martin Enrg.), on the south-cast by the land of the CNR, und on the south-west by lots 112 (CNR) and the town of Trois-Pisloles, and purl of lot one hundred and twenty (120) town of Trois-Pislole>.Georges D'Amours and J.-IL Duvul Inc.: the whole with buildings built thereon, circumstances and dependencies; subject to the servitude affecting lots one hundred and twenty and one hundred and twenty-one (120 und 121).\" To be sold at the registry office, division of Téiniscoiiala.ut the Court House, 33 dc la Coin Street, Rivière-du-Loup, on the THIRTIETH day of JANUARY.1970, ut TEN o'clock in the morning.Maurice Morin, Sheriff's Office.Sheriff.Rivière-du-Loup, December 12.1969.3237G M O N T M A G N Y Fieri Facias dv Bonis el de Terris i .iMaila \u2014 Province of Québec District of Montmagny Provincial Court, ( A RM AND CHABOT, Montmagny, J blacksmith, Sl-la-No.2590.J bien - dc - Panel, county \"f ' Montmagny, plaintiff, » JACQUES MONTMIN Y.St-Fabicn-.lo-Panel, county of Montmagny.defendant.\"A farm lying and situated in the municipality of St-Fnbicn-dc-Panct, county of Montmagny, formed of : (a) The loi known and designated under number ten ( 10) on Range five (R.V) on the ofh-cial cadastre of the township of Rolette: (b) A lot of land measuring twelve hundred feet (1200') in depth from the northwest t the southeast by u width of eight hundred and fifty feet (S50') measured from the northeast lo the southwest, that is, the width of the lot.taken from the lot und known und designulcd under QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1969, Vol.101, No.51 7105 rang cinq (Kg V) du cadastre officiel du canton Rolette, et borné comme suit: au sud-est au trait carré séparant les rangs cinq Jet six, au sud-ouest au lot numéro douze, mêmes rang et canton, dont partie ci-après décrite et partie appartenant à Hilairc Brisson, au nord-ouest au résidu dudit.lot onze appartenant à LagUCUX et un nord-csl au lot dix ci-dessus décrit; c) I'm terrain de la contenance approximative de vingt-sept pieds (27') en largeur dans sa ligne sud-csl et de quatre cents pieds (400') en largeur dans sa ligne nord-ouest par une profondeur de neuf cent quatre-vingt-dix pieds (990'), le tout plus ou moins, pris à même le lot connu et désigné sous le numéro douze (Ptie 12) du ning V (Kg V) du cadastre officiel du canton Rolette, et borné comme suit: uu sud-est au trait carré séparant les rangs cinq cl six, au sud-ouest à la route du comté, uu nord-ouest au résidu dudit lot douze appartenant ù Hilairc Brisson et au nord-est ù In partie du lot onze ci-dessus décrite en second lieu; l.e tout avec toutes les bâtisses y érigées, circonstances cl dépendances.» l'onr être vendu au bureau du shérif, 25.l'alais de Justice, Monliiiaguv, le VINGT-SKITIÈME jour de JANVIER, 1970, à TROIS heures de l'après-midi.Le .shérif.Bureau du Shérif, Jean-Paul Tiik.miii.av.Montmagny, le 11 décembre 1909.32377-0 Fieri Facias dc Terris Canada \u2014 Province de Québec District dc Bcauce < oiu IVoviiiciulc( OCOTT AUTOMOBILES Bcauce, ) *^ INC., corporation légale-No 112K.\\ ment constituée et ayant sa (.place d'affaires à Scott-Jonction, comté .7039 Trans-Canada Roofing Company.7040 Trc GaRo inc.7040 Trois-Rivières estimation inc.7040 Union des Gradués Inscrits à Laval (U.G.LL.) inc.7041 Viens (Roland) inc.7041 lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Association Québécoise du Judo Kodokan inc.7042 ( Ibemco Ltd.7042 Chcmco ltée.7042 Drakestone Corporation.7042 Drassel Corporation Inc.7045 Entreprises Fernand Séguin inc.(Les).7043 Friendly Wood Gatineau Ltd.7043 Groupe Sécurité inc.(Le).7043 Immeubles E.P.R.ltée.7043 Index Holdings & Management Ltd- 7044 Industries Brunelle inc.7044 Inter Continental Equipment and Supply Co.Ltd.7044 Ligue de Hockey Junior « B » Provincial du Québec inc.(La).7044 Lubri-Val inc.7045 Maison Pic XII.7045 Si-Pierre (Jules) ltée.7945 Security Group Inc.(The).7043 Service Super Sports ltée.7045 Société Drassel me.7045 Toulon Construction Inc.7046 Victoriavillc Furniture Limited.7040 Sieges sociuux Head Offices Agence Publigraphic inc.7003 Ameublement D.C.Télévision inc.7003 Avec inc.7003 II.1LC.B.Inc.7002 Beique (F.L.) inc.7062 Boucherie Idéale (Baie Comcaii) inc.7063 Cogena Inc.7064 < 'opema Inc.7065 Ferme La Cravache inc-.7065 Foyer Sacré-Coeur de Berthicrville inc.7064 Gilbert & Gilbert limitée.7063 1 labitat Matane Inc.7005 Hayden (Ross E.) Sales Inc.7064 La Malbaie Auto Parts Inc.7065 Langlois Holdings Ltd.7064 North End Paradise Development Corp.7064 O'Sullivan Business College Inc.7065 Paramount Specialties Ltd.7066 Placements Charlesbourg, limitée.7064 Placements Langlois ltée (Les).7064 Publigraphic Agency Inc.7063 Salmon (Neuville) & Associates Ltd.7066 Seminc Inc.7066 Staub (Rusty) Inc.7066 Transport du Lac ltée.7071 DEMANDES APPLICATIONS a la Legislature to legislature Baliary, Alfred A.7072 Syrian Greek Orthodox Church of St-Nicholas of Canada.7072 LIQUIDATION WINDING avis dc up Notices Caisse populaire dc Stc-Floreucc (La).7073 Couvoir coopératif de Nicolet.7074 Société coopérative agricole régionale dc St-Alcxis dc Matapédia.7073 Syndicat coo|>ératif dc téléphone Lotbinièrc.7074 Éducation Education Municipalité scolaire dc: School Municipalily of: Buckingham (Prot.) (Dem.-Appl.).7075 CEGEP Montmorency (L.P.).7075 Poltimore (Prot.) (Dem.-Appl.).7075 Institutions Financial financières, Institutions, compagnies Companies et coopératives and Cooperatives Compagnies de fiducie Trust et dc finance companies: National Trust Company (Agent).7072 Industry and Commerce Industrie et Commerce Avis de pêche aux coquillages.7073 Shell fishing notice.7073 Travail Labour Industrie ou métiers de: Industry or Trades of: Boites dc carton ondulé, Province (Mod.).7080 Corrugated paper boxes, Province (Amend.).7080 PROCLAMATIONS PROCLAMATIONS Abrogation de l'extension de la juridiction dc la Cour municipale dc la ville de Sainte-Foy nu village dc Notrc-Dainc-de-Lorctte, devenu la ville dc VAncicnne-Lorcttc.^^O\"* Abrogation of the extension of the jurisdiction of the Municipal Court of the city of St.Foy to the village of Notrc-Dame-de-Lorctte, which is now the town of l'Ancicnne-Lorette.7093 Annexation of a part of the territory of the municipality of the parish of Sain-tc-Croix, to the municipality of the village of Sainte-Croix, comté de Lotbinière.7094 Annexation of a part of the territory of the municipality of the parish of Saint-Cyprien to the municipality of the village of Napierville, county of Napiervillc.7096 7120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 décembre i960, 101' année, n° 01 PROCLAMATIONS PROCLAMATIONS (suite) (continued) Annexation of a pari of the territory of the municipality of the parish of Saint-Joscph-de-Maskinongc to the municipality of the village of .Maskinongé, county of Maskinongé.7097 Annexation of a part of the territory of the municipality of the parish of Sainte-Marie to the municipality of the parish of l'Enfant-Jésus, county of Beauce.7092 Annexation of a part of the territory of the municipality of Snint-Piiul-dc-Chatcauguay to the municipality of the parish of Sainle-Martinc.county of Chftteauguay.7099 Annexion (rune partie du territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Croix à la municipalité du village de Sainte-Croix, comté de Lotbinièrc.7094 Annexion d'une partie du territoire de la municipalité de la paroisse dc Sninl-Cypricn à la municipalité du village de Napierville, comté de Napierville.7090 Annexion d'une partie du territoire de In municipalité de la paroisse de Sninl-.loscph-dc-Mnskiuongé à la municipalité du village de Maskinongé.comté de Maskinongé.7097 Annexion d'une partie du territoire dc la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie à la municipalité de la paroisse de L'Enfant-Jésus, comté de Bcauce.7092 Annexion d'une partie du territoire de la municipalité de Sniiil-Paul-dc-Chà-tcauguay à ht municipalité de lu paroisse de Sainte-Martine, comte de Chftteauguay.7000 Civil Service Department Act i Kill 23) coming into force of the Act.710(1 Communications, entrée en vigueur de la Loi du ministère (Bill S7).70S1 Communications Depart nient Act (Bill S\") coming into force of the Act.70SI Fonction publique (bill 23) entrée eu vigueur île la Loi du ministère 7100 Provincial Secretary's Depart men I Act.coming into force of the Act repealing the Provincial Secretary's Depart-inenl Act and amending other legislative provisions (Bill SS).7102 Secrétariat, entrée en vigueur de la Loi abrogeant la Loi du secretarial el modifiant d'autres dispositions législatives ( Bill SS).7102 Holidays and public holidays.December 26, I960 mid January 2, 1970 7101 Jours île fêles publiques, 20 décembre 1909 et 2 janvier 1970.7101 RÉGIE tic lussurancc QUÉBEC.recolle du Quebec Crop Insurance Board Autumn Wheal .7070 Betterave sucrière.7075 Blé d'automne.7070 Pluc-curcd tobacco.7070 Sugar Beet .707\") Tabac jaune.7070 Régie dc l'électricité Electricity et du ga/.and Cas llonrd (in/.Métropolitain.Inc.(Application).7lirj SOUMISSIONS Si-Thomas, c.s.-s.c.TENDERS .7()!lll SYNDICATS Professionnels PROFESSION a.Syndicales Association des directeurs généraux des écoles (1909) (Const.-Inc.).Association du personnel de cadre, dc gérance cl de maîtrise de la fonction im)¦ IiiIm- du Québec (Const.-1ne.) .Syndicat des producteurs de luit nature du Bas St-Laurent (Const.-lue.) 7071 1)74 7il7à VENTES SHÉRIFS SA LUS SHERIFFS Iteuiicr Rentier Prévoyants du Canada (Les; rs Lessard 7103 I tea u liai -noix llvnlllllll nuis Central Mortgage and Housing Corporation (The) w Tcssicr.7103 Société centrale d'hypothèques el de logement (La) r* Tcssicr 7103 Kamouraska Kamatiruslm Raymond rs Dionnc Specialties Ltd.7104 Montmogn) Montmagny Chabot rs Miiiiliniiiy.7104 Scott Automobiles Inc.ro liissonncllc .7105 Montréal Montréal Bank of Montreal rs Boyd Neil : IB Banque dc Montréal rs Boyd Neil 7KB ( entrai Mortgage and Housing ( orpora lion (The) rs (iotllcl 71011 Dominion Building Materials (Montreal) Limited ro Colibri Construction liée.7 I'M.Dominion Building Materials (Monlrénl) Limited rs Colibri Construction Itce,.,./.,,.;.7107 Dominion Building Materials (Monlrénl) Limited rs Colibri Construction ltée.,.7107 Dominion Building Materials (Montreal) Limited r* Colibri Const nul ion Itce.7113 Greenfield Park Lumber ami Builders Supplies Ltd.ro Talbot.7I0S Grimard raJean Bélanger.Income Tax Act and amendments rs Mercuriadcs.¦ \"'' Loi de I'impAl el ses amendements r* Mercuriadcs .I.aplanie es Vian.\u2022 \"N Miilloni r* Roy.7110 Montco Company (1065) Ltd.ro Bélanger.7113 Morin rs Bleau et al.\u2022 \" Sociélé centrale d'hypothèques et dc logement (La) m Goulet.Trachman w llarncf.7110 Vachon (A.) Const met ion liée es Succession-Estate Doiiia Roy Beam licinin 71011 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 20, 1009, Vol.101, No.51 7127 Quebec Quebec \\gcnccs Lyon inc.(Les) w Cadrin.7114 Italique de Commerce Canadienne Impériale m Bienvenu.7115 Canadian Imperial Bank of Commerce rs Bienvenu.7115 i aisse populaire Notre-Dame de Québec i La) vs Isabel.7115 Roberval Robenal 'l'élu m Lange vin.7115 Saint -Fra n cois .Soin I-François (irenier rs Maclure.7117 Solo Acceptance Corporation rs Makel- vey.\"118 Sain l-llyaciii the Sainl-llyaciiilhc Alix rs Turgcon.7118 Témiscamingue Témiscamingue Ollicc du crédit agricole du Québec (L') rs Dcault.7121 Ollicc du crédit agricole du Québec ( L\") rs Goulet el al.7119 Québec Farm Credit Bureau (The) vs Dcault.7121 Québec Farm Credit Bureau (The) en Goulet el al.7119 Terrebonne Terrebonne St-Eustnchc Heady-Mix & Paving Ltd.;w W.1).Kciiuinckx.7121 Taxes Taxes Boucherville, villc-town.7053 Jonquière, cité-city.7052 Sl-Biisile-lc-Granil.ville-town.7050 "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.