Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 13 (no 41)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1973-10-13, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" £- GAZETTE s* OFFICIELLE DU QUÉBEC PARTIE 1 AVIS JURIDIQUES QUEBEC i~4; OFFICIAL » GAZETTE PART 1 JURIDICAL NOTICES GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n\" il 5829 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 parait le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Quebec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon ; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher 5830 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October IS, 1973, Vol.105.No.il TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion : 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: S5 des 100 mots.Exemplaire séparé: 81 chacun.Feuilles volantes: 83 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante : Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dobe.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation : $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1) : from 1 January to 31 December, $20; from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, 810.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings.Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1A 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1A IG7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis 107) Postage paid-in-caah \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973.105' année, n° U 5831 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives g;ves notice that pursuant to section 4, 5a and following of the Companies Information Act.the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed A B R FACTORS INC.A.C.SANITATION.A.P.M.INC.AGENCE KATIMAVTK INC.AGENCE KEETINC.AGENCES DÉRY INC.LES AGENCES DE ROUYN-NORANDA LIMITÉE.LES AGENCES ST-MAURICE INC.ALGARY CO.INC.ALLAN CARPET MILL INC.ALLIANCE DES PROPRIÉTAIRES DE GATINEAU.ALMA DEVELOPMENT QUÉBEC INC.AMEUBLEMENT ST-DENIS INC.AMEUBLEMENTS NOUVEAU-MONDE INC.ANDINOINC.ANDOVER INVESTMENTS LTD.ANSWEL DISTRIBUTIONS INC.ARMOREX INC.LES AS PEE WEE D'ALMA INC.ASSOCIATION CANADIENNE DE SKI AMATEUR (DIVISION DU QUÉBEC) ASSOCIATION DES CARNAVALS AMBULANTS DU QUÉBEC INC.L'ASSOCIATION DE CHASSE & PÊCHE DE DUPARQUET INC.L'ASSOCIATION DU FOOTBALL MINEUR D'ALMA INC.L'ASSOCIATION DU LAC DESMARAIS INC.Montreal.1965-72 et/and 1973 Dorion.1971 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1972 et/and 1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.Beauport.1971 à/to 1973 incl.Saint-Félix-du-Cap- 1970 à/to 1973 incl.Rouge Rouyn.1972 et/and 1973 Grand'Mcre.1971 à/to 1973 incl.Longueuil.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972-1973 Gatineau.1967 à/to 1973 incl.Brossard.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Mount Royal.1972-1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Aima.1973 Québec.1970 à/to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 Duparquet.1965, 1972 et/and 1973 Aima.1966 à/to 1973 incl.St-Denis-de-Brompton.1970 à/to 1973 incl. 5832 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.11 Nom de la compagnie Name of the company ASSOCIATION DES MARCHANDS DE MEUBLES AU DÉTAIL DU QUÉBEC INC.ASSOCIATION MONTELONGHESE DU QUÉBEC.L'ASSOCIATION DES PARENTS DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ST-DENIS INC.ATELIER NORIVE INC.AUTO REBUTS VALLEYITELD INC.AUTOMOBILES MINI PRIX INC.AUTO-SPORT PLESSIS.INC.B.C.D.ALUMINIUM LTD.B & H ÉLECTRIQUE INC.BAR SALON STE-HÉLÈNE INC.BELCRAFTINC.LA BELLE VISION (1972) INC.BERNARD AMUSEMENT INC.BIJOUTERIE ALMA LIMITÉE.AU BISTRO DES AMIS DU SPORT INC.BOUTIQUES LES IMPECCABLES INC.BOULANGERIE DEL SOLE INC.CADILLAC MOLV MINES LIMITED.LES CAMIONNEURS DE JOLIETTE & RÉGION, INC.LE CAMP DE VACANCES ARMAND DUBREUIL INCORPORÉE CANADIAN DANLYN TOOLS INC.CAN-AM EQUITY CORPORATION.«'EASAR'S PALACE INC.LA CENTRALE D'IMMEUBLES STE-FOY INC.LE CENTRE CULTUREL HENRY DESJARDINS INC.CENTRE DE DANSE DE MONTRÉAL INC.CENTRE D'ESCOMPTE MONT-ROYAL INC.CENTRE D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTIQUES POUR ELLE & LUI INC.LE CENTRE DES LOISIRS LACORDAIRE D'ALMA INC.LE CENTRE DE NETTOYAGE DE REPENTIGNY INC.CENTRE DE RÉCRÉATION LAC NOTRE-DAME INC.CENTRE DE SKI MONT ST-MATHIEU INC.CENTRES D-ÉTUDES SPÉCIALISÉES INC.CHEZ MILO LTÉE.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1957, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Druininondville.1970, 1972 et/and 1973 Salaherry-de-ValleyficId 1966.1967, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Plessisville.1967 et/and 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Longueuil.1970 à/to 1973 incl.Plessisville.1970 à/to 1973 incl.Trois-Rivière.1972 et/and 1973 Montréal.1972 et/and 1973 Alma.1965 à/to 1973 incl.Jonquiére.1970 à/to 1973 incl.Boucherville.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Val d'Or.1970, 1972 et/and 1973 Joliette.1903 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Laval.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1959, 1961, 1964, 1968 à/to 1973 incl.Hull.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Alma.1966 à/to 1973 incl.Laval.1968, 1969, 1971 à/to 1973 incl.Wentworth-Nord.1970 à/to 1973 incl.Trois-Pistoles.1972 et/and 1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n\" il 5833 Nom de la compagnie A'omf o/ the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed LA CIE ÉGIDE BRETON, LTÉE.CLAIIBERT INC.CLINIQUE D'ESTHÉTIQUE MARCO VERMET.CLUB DES AMBASSADEURS DE GATINEAU-BUCKINGHAM INC.CLUB AUTO SPORT D'ALMA INC.CLUB AUTOMOBILE DE LA DIABLE.CLUB DIAMANT.CLUB DE GOLF ST-MICHEL INC.CLUB DE GOLF TAWACHICHE.CLUB D'HIVER DE HULL INC.CLUB DE HOCKEY PORT ALFRED SENIOR INC.CLUB DE HOCKEY ROSEMONT JUNIOR INC.CLUB JUVAQUA D'ALMA INC.LE CLUB KINSMEN DE STE-ROSE INC.CLUB MEMO INC.LE CLUB DU MERCREDI.CLUB LES MONTAGNARDS DE LA TUQUE INC.LE CLUB DU NOUVEAU MONDE LTÉE.CLUB OPTIMISTE DU PLATEAU MONT-ROYAL.QUÉBEC INC.CLUB DE SKI & D'EQUITATION .HUSKY » INC.CLUB SOCIAL & SPORTIF DU LAC LABELLE INC.LE CLUB DES SPÉCULATEURS DE MONTRÉAL INC.CLUB SPORTIF BARI.LE CLUB SPORTIF DE DANVILLE.CLUB DE TENNIS D'ALMA INC.CLUB DE YACHT DE MONTMAGNY INC.CLUB DE YACHT DE LA RIVE.COLLÈGE MONTPELLIER INC.COMITÉ D'ÉDUCATION AGRICOLE INC.COMITÉ D'ENTRAIDE HOCHELAGA-MAISONNEUVE.COMITÉ DES LOISIRS DU LAC OPÉRA INC.COMITÉ DES LOISIRS DU SECTEUR ST-ALPHONSE.LA COMPAGNIE D'ALLUMETTES DE QUÉBEC, INC.LA COMPAGNIE DE DÉMOLITION LOGO INC.LA COMPAONIE D'IMMEUBLES DES TRAVAILLEURS EN FORÊTS LTÉE Aima.1970 a/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1909 A/to 1973 incl.Gatineau.1972 et/and 1973 Aima.1970 :\\/to 1973 incl.St-Jovite.1965 à/to 1973 incl.Hull.1960.1971 à/to 1973 incl.St-Michel.1966 à/to 1973 incl.St-Rémi.1970 à/to 1973 incl.Hull.1960, 1962, 1964 et/and 1908 Port-Alfre.1.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1901 à/to 1973 incl.Alton.1969 à/to 1973 incl.Ste-Ros«.1969 à'to 1973 incl.Montréal.1962 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.La Tuciue.1971 à/to 1973 incl.Aima.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Lac Lemoine .1966, 196S à/to 1973 incl.Lac Labelle.1966.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Danville.1971 à/to 1973 incl.Aima.1970 à/to 1973 incl.Montmagny.1969 à/to 1973 incl.Sorel.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.St-Sylvcre.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.St-Calixte.1971 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1972 à/to 1973 incl.Hull.1965 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Québec.1968 à/to 1973 incl. 58.34 QUÉBEC OFF ICI A I.GAZETTE, October 13.1973, Vol.105, No.kl Nom de la compagnie Same of the eomnanir Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1964 à/to 1973 incl.l'ointe-Catineau.1964, 1965.1968, 1971 à/to 1973 incl.Houyn.1964, 1966 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.St-Roch.1970 à/to 1973 incl.Mont-Joli.1971 à/to 1973 incl.Montmagny.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 Québec.1965 à/to 1973 incl.Ouébec.1972 et/and 1973 Montréal.1909 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montreal.1972 et/and 1973 Mount Royal .1966 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Monterai.1966 à/to 1973 incl.St-Laurcnt.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1964.1965.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.V.St-Michel.1962 à/to 1968 incl.1970 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1971 à/to 1973 incl.StrMichel.1969 à/to 1971 incl.et/ and 1973 Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Lasalle.1948, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1962.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1964.1969 à/to 1973 incl.COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DEMERS INC.LA COMPAGNIE DES MAISONS MODÈLES LIMITÉE LA COMPAGNIE MINIÈRE UTUFOltA LTÉE.LA COMPAGNIE NATIONALE D'ENTRETIEN ET DE LOCATION INC.CONFECTION ST-ROCH INC.CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DE LA MÉTIS INC.CONSEIL DES LOISIRS DE MONTMAGNV.CONSOLIDATED PLANNING, INC.LA CORPORATION DES AUDIOPROTHÊSISTES DU QUÉBEC LA CORPORATION DES PREMIERS JEUX D'HIVER CANADIENS INC.CRÉATIONS KAMICO LTÉE.CRÉATIONS PHVLOR INC.CRÉATIONS TISSUS VASILIO LTÉE .CROMBIE 4 FLEMING INVESTMENTS LTD.CROSSTOWN RESTAURANT (1904) LTD.LES CUISINES LAURENTIENNES INC.LES CUISINIERS INTERNATIONAUX INC.D.& H.REALTIES INC.D-J ENTERPRISES LTD.D.O.S.ENTERPRISES LTD.DA GIANOULIAS PIZZA RESTAURANT INC.DAKEN CONSTRUCTION (MONTREAL) INC.DAMAS INVESTMENT CORP.DANCING WATERS QUÉBEC LTD.DANDEE DONUTS INC.DANHEC FINANCE (INTERNATIONAL) LTD JEAN J.DANIS & ASSOCIÉS INC.DANSYL PREVISION PRODUCTS LTD.DANTE'S INC.LIONEL DAOUST, LIMITÉE.DARO VOYAGES (CANADA) INC.DAROC INC.DARON INVESTMENT CORP. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° 41 5835 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed PIERRE DAVID INC.DEL MIRO INC.DEL PAPA CONSTRUCTION INC DELISLE ET DELISLE LTÉE_____ DELI VILLE LTD.DELTA AUTOMOBILES INC.DELTA DISTRIBUTIONS INC.DÉMÉNAGEMENT ET ENTREPOSAGE VICTORIA LTÉE LE DÉMÉNAGEUR DU NORD LIMITÉE.DEMO ENTERPRISES LTD.ROGER J.DENIS INC.DENISON MINES (QUÉBEC) LIMITED.DEPENDABLE BUILDING MAINTENANCE CO.LTD.DÉPÔT DE PNEU (SHERBROOKE) INC.DERBY DEVELOPMENT CORPORATION.DESAULNIERS & FILS LTÉE.DESBIENS CONSTRUCTION LTÉE.:.PAUL DESCHAMPS INC.DESCHÊNES PLANING MILL CO., LTD.DESIGN ASSOCIATES AND REPRESENTATIVES INC.DESIGN WORSHOP LTD.GAÉTAN DESJARDINS INC.DES LA INC.ROGER DESNOYERS INC.H.DESPIRT & CO.LTD.DESPRÉS FEED & BUILDING PRODUCTS LTD.PAUL G.DESROCHES & ASSOCIÉS INC.DESSAULES AUTOMOTIVES INC.DEUX MONTAGNES ENTREPRISES INC.ROBERT DEVEAU (QUÉBEC) INC.LEOPOLD DEVEAULT INC.DIAGNOS INC.DOMAINE DU LAC MAURICE INC.DOMAINE DES LACS INC.DOMAINE LAFONTAINE LTÉE.St-Vincent-de-Paul.1962 :\\/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.St-Léonard.1965.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1965, 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.St-Antoine-des-Lauren- 1909 à/to 1973 incl.tides Montréal.1968 à/to 1973 incl.Victoriaville.1970 à/to 1973 incl.Sept-îles.1972 et/and 1973 Cl.âteauguay.1968 à/to 1973 incl.St-Léonard.1967, 1970 à/to 1973 incl.Quéliec.1967.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1970 à/to 1973 incl.Pointe-aux-Trembles.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Trois-Pistoles.1966, 1971 à/to 1973 incl.Lasaile.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.St-Antoine-des- 1971 à/to 1973 incl.Laurent ides Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1956, 1969 à/to 1973 incl.Ayec's Cliff.1969 à/to 1973 incl.Dollard-des-Ormeaux .1969 à/to 1973 incl.St-Hyacinthe.1958.1966, 1969 à/to 1973 incl.St-Eustache.1963 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Ste-Thérèse-Ouest.1967 à/to 1973 incl.Lachine.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1963, 1964, 1967 à/to 1973 incl.Montréal.1965, 1966, 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl. 5836 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.106, No.41 Nom de la compagnie Name of the company DOMAINE DE LA MONTÉE INC.DOMINION BUILDING MATERIALS (MONTREAL) LIMITED.DOUGLAS & DESJARDINS INC.E.B.C.ELECTRONICS COMPANY LIMITED.EASTERN MINE & TITLE INC.EASTERN MOLYBDENUM CORPORATION.ÉDITIONS DEMERS INC.LES ÉDITIONS DES DEUX MONDES LTÉE.LES ÉDITIONS GRAPHIQUES INC.LES ENTREPRISES A.L.M.LTÉE.L'ENTREPRISE D'ENTRETIEN MÉTRO INC.ENTREPRISES DIA INC.LES ENTREPRISES DELVIGI INC.LES ENTREPRISES DESBERGES INC.ENTREPRISES DESROCHES LIMITÉE.LES ENTREPRISES GAY'-NET INC.ENTREPRISES JACQUES DOYON.LTÉE.LES ENTREPRISES KE-MO LTÉE.LES ENTREPRISES MACHANTY INC.LES ENTREPRISES MEDICINA INC.LES ENTREPRISES NASSAU LIMITÉE.LES ENTREPRISES MAURICE BARIL INC.LES ENTREPRISES ROLAND INC.LES ENTREPRISES THERMO-VISION INC.ENTREPRISES X.MONGEON LTÉE.ENTRETIEN DELTAL LTÉE.EXCELLENCE COMPAGNIE D'ENTRETIEN INC.FEDERAL DELIVERY INC.FÉDÉRATION DU PLONGEON AMATEUR DU QUÉBEC.FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D'HISTOIRE DU QUÉBEC.FERME MOLAMO INC.FERME NORMAND CRÊTE INC.F LEUR Y' CUT RATE LTD.FORWARD COMMUNICATIONS INC.Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Brownsburg.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montréal.1972 et/and 1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Mont real.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Lachine.1972 et/and 1973 Pointe-Claire.1967 à/to 1969 incl.1971 à/lo 1973 incl.Drummondville.1971 à/to 1973 incl.Laval.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1968 à/to 1973 incl.Beloeil.1963, 1964.1966 à/to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 Ste-Martine.1969 à/to 1973 incl.Repentigny.1965 à/to 1973 incl.Rosemont.1970 à/to 1973 inel.Laval.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1964.1966.1970 à/to 1973 incl.Gatineau.1963 à/to 1966 incl., 1970.1972 et/and 1973 Montréal.1965.1968 à/to 1973 incl.Shawinigan.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 St-Basile-le-Grand.1967 à/to 1973 incl.St-Urbain-Premier.1973 Angers.1967 à/to 1973 incl.Saint-Laurent.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969, 1971 à/to 1973 incl.Québec.1961, 1962, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1965 à/to 1973 incl.Saint-Lin.1967 à/to 1970 incl., 1972 et/and 1973 Dundee.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° 11 Nom de la compagnie Same of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed 4 LAKES DEVELOPMENT CORP.FRANTZ CUSTOM MADE DRAPES.LIMITED.G.K.S.INVESTMENTS LTD.G.L.CONSTRUCTION INC.G.L.LUMBER CO.LTD.G.& P.MACHINING & WELDING INC.GALERIE DENYSE DELRUE (MONTRÉAL) LTÉE LES GALERIES JACQUES CARTIER INC.GARAGE CROUSSET & GENDRON INC.GAROH LTD.F.GAUTHIER & FRÈRE LIMITÉE.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1964.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1969 incl.et/ and 1972 à/to 1973 Terrasoe-Vaudreuil.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Mount Royal.1970 à/to 1973 incl.Les Méchins.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1973 Sorel.1963.1966, 1967, 1973 WILLIAM GÉLINAS INC.Sha«inigan 1969.1972.1973 GENERAL AERO INC.GLENELG REST HOME INC.St-Andre-Avellin.1970 à/to 1973 incl.Lasalle.1950.1957, 1959.1960 1963, à/to 1968 incl.1971 à/to 1973 .Westmount.1969.1972.1973 .Hull.1964, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1959.1965, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Anjou.1972, 1973 .Sorel.1964 à/to 1973 incl.Riniouski.1967 à,'to 1973 incl.Thetford-Mines.1969, 1971 à/to 1973 incl.HÔPITAL GÉNÉRAL DE ST-HYACINTHE.St-Hyacinthe .1963.1971 à/to 1973 incl.GLENGARRY CORPORATION LIMITED.GLENWOOD SERVICES LIMITED.GLOBAL IMPORTERS LTD.GLOBUS INTERCONTINENTAL LAND CORP GLOIRES DE PARIS INC GOLDEN JOY RESTAURANT INC.GOLDEN LION INVESTMENTS LTD.THE GOLDEN WAX JEWELLERY CO.LTD GOLDTERRE CORPORATION LIMITED.GOLFE EQUIPMENT INC.DAMIEN GRENIER LTÉE.HÔTEL GODMAIRE INC.HÔTEL LE NATIONAL INC.HÔTEL MAURICE (1961) LIMITÉE.HÔTEL MOTEL AMICO INC.HÔTEL PLAZA D'ALMA LIMITÉE.LES IMMEUBLES LEVY LTÉE.LES IMMEUBLES MINUIT LTÉE.LES IMMEUBLES PORT MAURICE INC.Port-Alfred.1959.1961 à/to 1964 incl.1971 à/to 1973 incl.Port-Alfred.1969 à,to 1973 incl.St-Jérôme.1961.1966 à/to 1973 incl.Laterrière.1972, 1973 St-Joseph-d'Alma.1963, 1964, 1968, 1970 à' to 1973 incl.Lévis.1970, 1971, 1973 Chomedey.1964 à/to 1973 incl.Lasalle.1971 à/to 1973 incl. 5838 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.il Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapportai non produits Returns not filed IMMEUBLES KEMATT LTÉE.LES IMMEUBLES WALTEK KELLY INC.IMPRIMERIE MIKADO INC.LES INDUSTRIES JOBERT INC.LES INDUSTRIES NASRAL LTÉE.INTER MARKETS LTD.INTERNATIONAL PERSONNEL CONSULTANTS LIMITED.INTERNATIONAL TRANSCENDENDAL MEDITATION SOCIETY INC.J.I.M.INCORPORÉE.JEURAMA INC.JOEY'S SERVICES LTD .LE JOURNAL DE DRUMMONDVILLE INC.KAPPA DELTA OFFICE EQUIPMENT INC.KA-Y INVESTMENTS CORP.MAY KAY RESTAURANT INC.Hull.1968 ft/to 1973 incl.Deux-Montagnes .1969 à/to 1973 incl.Laval.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.St-Georges .1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Dorval.1970 à'to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Longueuil .1972, 1973 Alma .1965 à/to 1968 inc.Westmount.1968 à/to 1973 incl.Sherbrooke 1966.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.St-Laurent 1955.1967 à/to 1973 incl.St-Laurent .KELLY & KELLY INC KENMONT REALTY LIMITED KENT VARIETY STORE INC Iberville Montreal.Montreal.KEVV INVESTMENT INC.KIAMIKA INVESTMENTS CO.LTD KIEL CONSTRUCTION INC.THE KILTIE CO.LTD.KIM INTERNATIONAL MUSIC CORPORATION KINDERSLY CORPORATION KINGSLEY HOUSE INC.KINGSWOOD (1969) INC KING-WELL INVESTMENT INC LES KIOSQUES DU MÉTROPOLITAIN INC.KIT-LICA FURNITURE INC KNITBROOK JRS.INC L.A.MEAT MARKET INC.LABELLE & LORTIE INC.LABORATOIRES DELTA INC.LABORATOIRES FER-AUR COMPAGNIE LIMITÉE 1965 à/to 1967 incl.et/ and 1970 à/to 1973 incl.1966.1970 à/to 1973 incl.1962.1963.1964, 1969 à/to 1973 incl.1966.1967.1969 à/to 1973 incl.'969 à/to 1973 incl, 1967 à to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1961.1967.1969 à/to 1973 incl.1963 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1966 incl.et/ and 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montréal .1970 à/to 1973 incl.Montréal.196-1 à/to 1973 incl.Montreal .Mont-Laurier Montréal.Lcnnoxville .t'homedey Montreal.Montreal.Pont-Rouge Montréal.1968 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° Al 5S39 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapporta non produits Returns not filed LABRADOR NICKEL MINING CORPORATION.Montreal.ROCH LA BRÈCHE LTÉE.Maple Grove.LACANO LTÉE.LACHINE SUPER MARKET INC LACMA MOTO CLUB INC.LAFENICE RESTAURANT INC.LAFORTUNE IMMEUBLES INC.LAITERIE PICARD 4 FILS INC Saint-Jan vier-dc-Blainville Lachine.Alma 1964 à/to 1973 incl.1966 et/and 1969 à/to 1973 incl.1967 à.to 1973 incl.1966-1954-1967 et/and 1969 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.LAJEUNESSE CONSTRUCTION LTÉE.LAKESHORE THEATRES LIMITED.LALIBERTÉ 4 MAURAIS INC.Cap-de-lu-Madeleiti Montréal.1968 à/to 1973 incl.Saint-Lin.1967-1969 à/to 1973 incl.St-Gilbert.1966-1968 et/and 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 â/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.LANESSA KNITTING INC.JOS.LAROCHE TRANSPORT INC.LAURENTIAN SILICA MINES COMPANY LIMITED LEVESQUE 4 ST-AMOUR INC.LOCK & KEY SUPPLY CO.LTD.LOISIRS CULTURELS RENÉ GODIN INC LOISIRS EAST-HEREFORD.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Mansfield.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1960-1964 et/and 1973 Lasalle.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1969-1970 et/and 1972- 1973 Asbestos.1967 à/to 1973 incl.Hereford 1967-1968 et/and 1972-1973 LON-DEN INC.LUXOR LIMITED MB SHOWROOM INC.M A M SALES CORPORATION.M.R.M.INDUSTRIAL FOODS LTD .MAGASIN DESCOMPTE PAT LTÉE.MAGNO INVESTMENTS LTD .B.MARTIN INC.MASSDALE REALTIES INC.MATÉRIAUX PRÉFABRIQUÉS QUÉBEC INC MATOM INC.MATRAY INC.MATUS TRADING CO.INC.MAXAAR REALTY 4 INVESTMENT CO.LTD MAXHERB INVESTMENT CORP.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Pont-Viau.1962-1967 el/and 1960 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1970-1972-1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972-1973 Hauterive.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Alma.1966 et/and 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Iberville.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1959-1960-1966 et/and 1969 à/to 1973 incl.St-Michel.196S à/to 1973 incl. 5840 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.11 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed JOHN MCFAUL & SON LIMITED.MEADOW-WEST BUILDING CORP.MCKEATING TRANSPORT CO.INC.MCQUADE HOLDINGS LTD.MECDRAIN LTD.MEDAL REALTIES LTD.MEDIA-POSTE INC.MEDICA COMPANY LIMITED.MELGO INVESTMENTS LTD.MENARD READY MIX LTD.MENETIATIAN SOCIETY OK MONTREAL MENSCHEN INC Lachute.1972, 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1966 incl., 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Westmount.1968 à/to 1973 incl.Hull.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1967, 1969, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.MERCERIE NOTRE-DAME LTÉE.Montréal.1963, 196S à/to 1973 incl.PHILIPPE MERCIL LTÉE.MERIDIONAL CONSTRUCTION INC MÉTALPHOTO CORP.Montréal.1959.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Québec.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965.1970 à/to 1973 incl.METCALFE CLEANERS INC.MÉTRO NOUVEAUTÉS INC.Ancienne-Lorette.1970 à/to 1973 incl.MÉTRO PARACHUTE CLUB INC .MÉTRO SURPLUS INC.METROMONT INC.METTANO PAPER PRODUCTS LTD.MEUBLIERS LIMITÉE.MEUBLO-RAMA INC.St-André-Avellin.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.MI VAL CANADA INC.Jonquicre.1968.1969 1971 à/to 1973 incl.MIADEL DEVELOPMENT CORP.MIAMI CONSTRUCTION INC.MIDDLE-EASTERN INVESTMENT CORPORATION.MID-KEBEK MINING CORPORATION.MIGUEL'S INC.MILAN-INTERNATIONAL SHOP INC.MILORNE INVESTMENT CORP.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.MIL-STANDARD SCREW PROD.CO.LTD. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.13 octobre 1973.105' année, n° Al 5841 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapporta non produits Returns not filed MIMOZA PIZZERIA & RESTAURANT LTD.MINE MANUFACTURING CO.LTD.MINGO INTERNATIONAL LTD.MINTZ FASHIONS LTD.MISS MONTREAL RESTAURANT INC.MOBERINC.I MOBILAB INC.».MODE DE VILLE INC.MODON CORPORATION.MOLISE CONSTRUCTION LIMITÉE.MOLYBIA MINES.LIMITED.MOMAT INC.MONACO SILK SCREEN INC.MONGESCO LTÉE.MONTFORT CONSTRUCTION INC.MONTACIER LTÉE.MONTANA STEAK HOUSE INC.MONTARVILLE INVESTMENT CORPORATION.MONTEN CORPORATION.MONTICO LIMITED.LE MONTMORENCY LIMITÉE.MONTNORTH REALTIES LTD.MONTREAL ANALYTICAL SERVICES LTD.MONTSOGE INC.MONTOUR CONSTRUCTION INC.MONT-ROYAL MUSIQUE INC.MONT-ROYAL PETROLEUM INC.MONTVILLE INVESTMENTS INC.MOOSHLA GOLD MINES CO, (1937) LIMITED.THE MOUNT BRUNO CURLING CLUB INC.MOUVEMENT DÉMOCRATIQUE PORTUGAIS INC.MOUVEMENT INTERNATIONAL D'AMITIÉ.MUDLAC GOLD MINES LIMITED.NEUVILLE ENTERPRISES INC.NEWKIRK SECURITIES LTD.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1964.1967 à/to 1969.1971 à/to 1973 incl.St-Hyacinthe.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.St-Michel.1964 à/to 1973 incl.Outremont.1969 à/to 1973 incl.St-Georges.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.St-Luc.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.St-Lambert.1960, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Lachine.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972.1973.St-Eustache.1960 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Laval.1972, 1973 Toronto.1967, 1972, 1973 St-Bruno-de-Montarville 1962, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1961 incl., 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1962, 1968 à/to 1973 incl. 5842 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973.Vol.105, No.il Nom de la compagnie -Vame of the company Adresse Address Rapporta non produits Returns not filed NIOUDETTE INC.ORGANISATION DES LOISIRS DE LACHUTE INC.P.A.L.MUSIC CORP.LTD.ANDRÉ PAQUETTE AUTOMOBILES INC.AU PATELIN DE L'AMITIE INC.PARTI DÉMOCRATE (DU QUÉBEC).PATSILK INVESTMENT CLUB INC.PERFECT DATA SYSTEMS INC.PIERRE TRANSPORT LTÉE.PINE HAVEN CONSTRUCTION INC.LES PISCINES AMOVIBLES INC.PISCINES MERMAID (QUÉBEC) INC.PIZZA PAN (CRESCENT) LTD.PLACE D'ESCOMPTE JAN INC.PLACE JEAN-BRILLANT INC.PLACE WEENA INC.LES PLACEMENTS DENIS INC.PLOMBERIE D'EXPERTS INC.LES PLACEMENTS DESMANO INC .LES PLACEMENTS DESMARAIS INC.LES PLACEMENTS DESROCHERS INC.LES PLACEMENTS LAFAYETTE INC.LES PLACEMENTS LAMARCHE INC.PLACEMENTS MEILLEUR INC.LES PLACEMENTS MONDRUM INC.LES PLACEMENTS DE ST-LUC INC.PLACEMENTS TERRASSE LACORDAIRE INC.PLAGESTIN MONTRÉAL INC.PLEXI LAMPS DECOR OF MONTREAL LTD.PLOMBERIE ET CHAUFFAGE BOURPO LTÉE .PNEUS RIVIERA INC.J.-DENIS POIRIER INC.GUY POISSON INC.PRECISION SOLID STATE DEVICES INC.Lachine.1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Lachute.1971 à/to 1973 incl.Dorval.1970 à/to 1973 incl.Gatineau.1972,1973 Ormstown.1968.1970 à/to 1973 incl.Laflèchc.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1973 Montreal.1972 à/to 1973 Grand'Mére.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1961, 1967 à/to 1970 incl.1972,1973 Anjou.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972 à/to 1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1967, 1969 à/to 1973 St-Laurent.1972, 1973 Sherbrooke.1968 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1963.1964.1967 à/to 1973 St-Gabriel-de-Brandon .1967 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1962 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Drummondville.1969 à/to 1973 incl.St-Luc.1972,1973 Montréal.1970 à/to 1973 inci.Montréal.1973 Montreal.1972, 1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl.Laval.1969 à/to 1973 incl.Salaberry-de-Valleyfield.1965, 1967 à/to 1973 incl.Tracy.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, no Al 5843 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapporta non produits Returns not filed PREISSAC MOLYBDENITE MINES LIMITED.PRESTO INVESTMENTS LTD.(N.P.I.).PROMOTION NORDIC INC.(LES).PROTECTION MÉCANIQUE INC.LES PUBLICATIONS MONTARVILLE INC.LES 4 LACS DES SABLES INC.QUÉBEC MATERIALS INC.QUÉBEC MÉDIA-SERVICE INC.QUÉBEC MONOBLOC INC.QUÉBEC QUARRYING & MINING CORPORATION (1965) LTD.QUÉBEC THREAD MILLS LTD.QUÉBEC THREADS INC.QUÉBEC VOYAGEURS CLUB INC.R.8.DETERNET INC.RAPID AUTO REPAIRS INC.RAYCO AMUSEMENTS LTD.RÉNOVATIONS ALOUETTE INC.RESTAURANT MIRAMAT LTÉE.LE RESTAURATEUR DE LA MONTÉE INC.ROBERTS CONSULTANTS INC.ROC-AL TRANSPORT INC.LES ROULOTTES FRONTENAC LTÉE.ROYAUME DU CHEVEU D'OR LTÉE.C.RUSSEL LIMITED.RUSTEX MINING CORPORATION.ST-DAMIEN FOODS CORP.LOUIS ST-DENIS & FILS INC.ST-DBNIS STREET HOLDINGS LTD.ST-JOHNSBURY TRUCKING CO.LTD.SAINT-LAURENT IMPORT LTD.SALNTE-LUCIE (SANTA LUCIA) PIZZERIA INC.S.N.D.M.ENTERPRISES LTD.SALON DE CHAUSSURES TOUSSAINT LTÉE.SALON SERGE MASQUER INC.SEALITE GLASS (QUÉBEC) LTD.SERVICE D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL IDÉAL INC.Montreal.1972.1973 Montreal.1972, 1973 Ste-Foy.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.St-Bruno-de-Montarville 1966 à/to 1973 incl.Laval.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1960, 1964, 1965, 1967 à/to 1973 incl.Aima.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Québec.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 ittcl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.BrownsbUrg.1971 à/to 1973 incl.Lasalle.1970 à/to 1973 incl.V urémies.1969 à/to 1973 incl.Laval.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Bristol.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Waterloo.1967, 1973 Montréal.1965à/to 1967incl\u201e 1969.1971 à/to 1973 incl.Dorval.1965.1966, 1970 à/to 1973 incl.St-Laurent.1968 à/to 1973 incl. 5844 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13.1973, Vol.105, No.Al Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed SERVICE INTER LIMITÉE.SERVICES D'AMBULANCE GODIN LTÉE.LES SERVICES D'HÔTELLERIE MARITIME LTÉE.SHELTON MODELS INC.SIR JOHN'S LAKE CLUB INC.SOCIÉTÉ D'ANALYSE FINANCIÈRE PF INC.LA SOCIÉTÉ D'ANESTHÉSIE ET RÉANIMATION DE SHAWINIGAN INC.SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE QUÉBEC-HAÎTI.SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN EPCO LTÉE.LA SOCIÉTÉ D'ESCOMPTE DE MONTRÉAL LTÉE.LA SOCIÉTÉ MILDO INC.SOCIÉTÉ MIPOGON INCORPORÉE.LA SOCIÉTÉ SOFOX INC.SOCIÉTÉ D'EXPANSION DE ST-NICOLAS LTÉE.LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE L'ÎLE JÉSUS.SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DE MARIA INC.SOGESPEX INC.LE SOLEIL DE MER LTÉE.SOMIT CO.LTD.MICHEL J.SORIN INC.SPÉCIALITÉS DE CONSTRUCTION G.M.LIMITÉE.STANDARD IRON MINING CO.LTD.STANDARD IRON WORKS LTD.STANSTEAD COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION INC.STATION FINA DEQUEN LTÉE.STUDIO D'AMAIGRISSEMENT FORME MIRACLE NO 16 INC.STUDIO D'AMAIGRISSEMENT FORME MIRACLE DE L'EST INC.STUDIO D'AMAIGRISSEMENT FORME MIRACLE DE ST-JÉRÔME TAPIS JEAN M.DAIGLE LIMITÉE.TEMPO REALTIES LTD.TIFFANY MILLS INC.TIM LAKE HOLDINGS LTD.TIP TOP CRÉATIONS INC.MAURICE TOUGAS LTÉE.TRADE-WINDS INTERNATIONAL LTD.Duvernay.1971 a/to 1973 incl.Montréal.1972, 1973 Québec.1967 :\\/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Lachute.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Shawinigan.1972, 1973 Québec.1967.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1904 à/to 1973 incl.Beauport.1969, 1972, 1973 Weir.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.St-Nicolas.1965 à/to 1973 incl.Ste-Rose.1970 à/to 1973 incl.Maria.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1907 à/tp 1973 i ncl.Montreal.1973 Montréal.1969.1972, 1973 Québec.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1968 à/to 1970 incl.1972, 1973 Stanstead .1972.1973 Aima.1967.1968, 1971 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1972.1973 Montréal.1972.1973 St-Jérôme.1972, 1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970.1972, 1973 Montréal.1965, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1973, 105' année, n° Al 5845 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed TRANSPORT DES MONTS LTÉE.Cap-Chat.TRANS-WORLD INVESTMENTS LTD.TRI-ORE MINING CORPORATION LTD.TRUDEAU LUMBER INC.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.St-Louis-de-Gonzague.1967, 1968, 1970 à/to 1973 incl.UNICRETE READY-MIX INC.UNION MARKING DEVICES INC.VERA PIZZA RESTAURANT LTD.Pincourt.1960, 1961, 1962, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1968,1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.MAURICE VERVILLE LIMITÉE.Chicoutimi-Nord.1965 à/to 1973 incl.THE VICTORIAN ORDER OF NURSES (MILLE ÎLES Rosemère.1969, 1971 à/to 1973 incl.BRANCH) LES VILLAS DEUX MONTAGNES LTÉE.Montréal.1969, 1971 à/to 1973 incl.VINI-GLASS INC.WESTMOUNTING PRODUCTIONS INC.WORLDWIDE MAIL ORDER SERVICE CORPORATION.H.G.WORRELL CONSULTANTS LTD.ZEFARO INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD.Waterloo.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1967 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1959, 1968 à/to 1973 incl.63909-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.53909-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Lettres patentes ( 1 \"' partie) Letters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date A.M.REALTIES INC.LES IMMEUBLES A.M.INC.LES ACCESSOIRES PAVOIS INC.ADMAQUE INC.ADMINISTRATION ALBERT INC.ALBERT ADMINISTRATION INC.6510 Wilderton, Montreal.17 08 73 Trois-Pistoles.13 09 73 656, La Suète, Sainte-Foy.17 08 73 15 Athlone, Place Bonaventure, 06 09 73 Montréal.Laval.15 08 73 AGENCE G.B.INC.ALARME ÉLECTRONIQUE FÉDÉRALE INC.1648, de l'Eglise, Montréal.17 08 73 FEDERAL ELECTRONIC ALARM INC.ANNA-LISA LINGERIE LTD.LINGERIE ANNA-LISA LTÉE.Montréal.04 09 73 5846 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 18, 1973, Vol.105, No.41 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date APPARTEMENTS CYBÈLE INC.ASTROLAB INC.ATELIER LEA INC.LES ATELIERS SOLIEECT LTÉE.LES ATELIERS WARWICK LTÉE.L'AUBERGE DES TROIS-CHEMINS INC.LES AUTOMOBILES LÉPINE INC.LÉP1NE AUTOMOBILE INC.AUTOMOBILES VAL D'OR INC.MARINA JEAN BEAUDOIN INC.A.BEAUPARLANT INC.PAUL H.BERGERON INC.BETEC TELECOMMUNICATIONS INC.TÉLÉCOMMUNICATIONS BETEC INC.BIJOUX C.L.R.LTÉE.C.L.R.JEWELS LTD.BINNACLE INVESTMENTS LTD.LES PLACEMENTS HABITACLE LTÉE.BOUCHERIE LA BOUCANERIE LIMITÉE.BOUTIQUE CHEZ HERMINE INC.CHEZ HERMINE FASHIONS INC.BOUTIQUE CICUREL INC.BOUTIQUE DE CADEAUX BLUENOSE LTÉE.BLUENOSE GIFT SHOP LTD.BOUTIQUE DE L'HABIT DE DOLBEAU INC.BOUTIQUE DE L'INFIRMIÈRE DU QUÉBEC INC.BOUTIQUE INOUIK INC.BOYER ET ROBERT LTÉE.BRASSERIE CANDIAC INC.BRIDEL INC.LA CANARDIÈRE DATSUN (1973) INC.CENTRE DE PAPIER PEINT CONTINENTAL INC.CONTINENTAL WALL FASHIONS CENTER INC.CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES EN PARA-PSYCHOLOGIE G.O.INC.LE CHAUSSETIER DE BEDFORD.LTÉE.CINESCOPE LTÉE.CINESCOPE LTD.CLOISONS U.P.INC.U.P.DRYWALL INC.395, Desrosiers.Matane.02 08 73 14, Windsor, Sherbrooke.22 06 73 Saint-Chrysostome.22 08 73 Ville St-Georges, Beauce.16 08 73 Warwick.29 08 73 Route 2, Montmagny.17 08 73 Plessisville.30 07 73 Val d'Or.25 09 73 25, 94e Avenue, Pointe-aux-Trembles.03 07 73 Lanoraie-d'Autray.07 08 73 3330, rue Petitclerc, Giffard.04 09 73 Montréal.04 04 73 Saint-Bruno-de-Montarville.20 08 73 Montréal.31 08 73 170 Wilson Boulevard, Longueuil.20 09 73 201 Lisit Street, Chàteauguay Centre.24 08 73 1227 Mount Royal Street East, 31 08 73 Montreal.Saint-Laurent.10 09 73 546, Boulevard Walberg, Dolbeau____ 04 09 73 Montréal.14 09 73 6363, rue St-Hubert, Montréal.21 02 72 Montréal.11 09 73 176, boulevard de l'Industrie, Candiac.12 09 73 145.Notre-Dame, Drummondville.13 09 73 1590, boulevard de la Canardière.28 08 73 Québec.1285 Hodge Street, Saint-Laurent____ 31 08 73 10680.boulevard d'Auteuil, Montréal.04 07 73 Bedford.07 09 73 5500 Bradford Place, Montréal.23 08 73 183, Larochelle, Kepentigny.18 04 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° Al 5847 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date CLUB BEN ET RICHARD INC.CLUB DE GOLF CONTINENTAL INC.CONTINENTAL GOLF CLUB INC.CLUB LE GRAND MARNY INC.COGEl'T LTÉE.COMMANDES POSTALES GLOBE INC.GLOBE HI AIL ORDER INC.COMMERCE DE DENRÉE DE MONTRÉAL LTÉE.MONTREAL COMMODITY TRADING LTD.LES COMMUNICATIONS SUR LES SOINS DE SANTÉ H.C.C.INC.H.C.C.HEALTH CAKE COMMUNICATIONS INC.LA COMPAGNIE COMMERCIALE GRANDE CHINE LTÉE.GREAT CHINA TRADING CO.LTD.COMPAGNIE DE SON ET DE TÉLÉCINÉMA RuPHE LTÉE.COMPAGNIE DES MÉTAUX MARYANN LTÉE.MARY ANN METALS COMPANY LTD.LA COMPAGNIE EHRLER LTÉE.EHRLER CO.LTD.CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES (MONTRÉAL) INC.HUMAN RESOURCES CONSULTANTS (MONTREAL) INC.CONSTRUCTION AQUILA INC.AQUILA CONSTRUCTION INC.CONSTRUCTION F.LUSSIER INC.CONSTRUCTION KIN INC.KIN CONSTRUCTION INC.CONSTRUCTION Z.A.R.INC.Z.A.R.CONSTRUCTION INC.LES CONSTRUCTIONS F.WALSH INC.F.WALSH CONSTRUCTION INC.LES CONSTRUCTIONS LENTEC INC.LES CONSTRUCTIONS ROLLAND CHICOINE INC.LES CONSTRUCTIONS TERRAC INC.CORPORATION ANTIMEX.ANTIMEX CORP.CORPORATION BEEKAY.BEEKAY CORPORATION.CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ONTARIO-ST-LAU-RENT.ONTARIO-ST.LAWRENCE DEVELOPMENT CORPORATION.Petite Matane.29 08 73 Paroisse Sainte-Victoire.Richelieu .17 08 73 2077 Victoria Street, Montreal.27 08 73 Montréal.23 08 73 1231 St.Catherine Street West, 29 08 73 Montreal.066 Sherbrooke Street.West, Montreal 21 08 73 Montréal.14 08 73 Montréal.04 09 73 1157, Van Horne, Montréal.3 1 08 73 1S04 de La Salle Avenue, Montréal.07 09 73 Montreal North.19 09 73 Montréal.21 08 73 Montréal.14 08 73 133, rue Principale.Saint-Edouard,.30 08 73 6136 Place Lacombe, Saint-Léonard.11 09 73 34 Valerie Street, Kirkland.30 08 73 490.boulevard Provenrher, lirossard.lô 08 73 5155 Sherbrooke Street West, Suite 07 09 73 319, Montreal.40.rue Clemenceau, Repentigny.23 05 73 407.rue Main, Gatineau.05 09 73 71, rue Duchastel.Outremont.06 09 73 400 de Maisonneuve Boulevard West, 21 08 73 Suite 110U, Montreal 1315 de Maisonneuve Boulevard West 27 08 73 Suite 620, Montreal 107. 5848 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.il Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date CORPORATION DE STATIONNEMENT SAFEWAY.SAFEWA Y PARKING CORP.CORPORATION DES MACHINES SUPRÊME.SUPREME MACHINE CORP.COSTAIN (QUÉBEC) LTÉE.COSTAIN (QUÉBEC) LTD.CRÉATIONS PIERRE YVES INC.PIERRE YVES CREATIONS INC.D'ARAGON, RUFIANGE & ASSOCIATES INC.D'ARAGON, RUFIANGE & ASSOCIÉS INC.SOLANGE DEMERS INC.DÉMOLITION TURCHETTA LIMITÉE.TURCHETTA DEMOLITION LIMITED.R.H.DENONCOURT & FILS INCORPORÉE.DESCHÊNES & VALOIS INC.GEORGES DESLANDES INC.LES DISQUAIRES ASSOCIÉS OPUS INC.LES DISQUES SOMET INC.DISTRIBUTION COUSINEAU INC.DISTRIBUTION OPUS (QUÉBEC) INC.DOAG INC.LE DOMAINE LEMIEUX INC.DOMIRO LTÉE.DOMIRO LTD.DRUMMOND MOBILE QUÉBEC INC.EAU DE SOURCE ALASKA INC.EDIRIV INC.ENTREPÔT DE MEUBLES DE LONGUEUIL INC.LES ENTREPÔTS NORDIQUES LIMITÉE .NORDIC WAREHOUSING LIMITED.LES ENTREPRISES ALAIN & DENIS LTÉE.LES ENTREPRISES CLÉOPHAS INC.LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FORGET INC.LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ROBERGE & LAMBERT INC.LES ENTREPRISES G.TOUCHETTE LTÉE.G.TOUCHETTE ENTERPRISES LTD.LES ENTREPRISES GADUPLO INC.400 de Maisonneuve Boulevard West, 07 09 73 Montreal.10215 St.Lawrence Boulevard, Mont- 07 09 73 real.Montréal.13 09 73 2110 Crescent, Suite 2.Monlreal.22 08 73 1800 Dublin, Laval.27 08 73 Saint-Chrysostome.22 08 73 6052 Boyce.Montréal 427.23 08 73 3, boulevard Ste-Croix, Victoriaville 29 08 73 Hauterive.04 09 73 Saint-Alexis.08 08 73 751, Jarry est, Montréal.13 08 73 189, chemin Rockland, Mont-Royal.29 08 73 456, rue Dollard.LaSalle.06 08 73 761, Jarry est, Montréal.13 08 73 204, rue Wellington nord, suite 4, 29 08 73 Sherbrooke.Saint-Léon.18 06 73 Montréal.23 08 73 700, boulevard St-Joseph, Drummond- 11 09 73 ville.874, boulevard de Lacliapelle.Pointe- 14 10 72 Calumet.1470 Peel Street, Montreal.29 08 73 2465, chemin Chambly, Longueuil.01 02 73 Montréal.29 08 73 Sainte-Béatrix.22 06 73 6365, Napoléon, Saint-Louis-de-Terre- 29 08 73 bonne.140, boulevard Ste-Rose, Laval.08 08 73 12156 Forsythe, Pointe-aux-Trembles.10 09 73 Granby.05 09 73 700, 128e Rue, Shawinigan-Sud.10 09 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105- année, n° 11 5S49 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date LES ENTREPRISES GÉRARD OUELLETTE INC.GÉRARD OUELLETTE ENTERPRISES INC.LES ENTREPRISES HERMES INC.LES ENTREPRISES J.R.G.LTÉE.LES ENTREPRISES L.MERCIER INC.LES ENTREPRISES M.R.INC.LES ENTREPRISES QUEUROP INC.LES ENTREPRISES RAYMOND BERNIER INC.ENTRETIEN MARSEILLES LTÉE.MARSEILLES MAINTENANCE LTD.EQUIFAB INC.ESTIMATION C.R.INC.EXPRESS MIRABEL INC.MIRABEL EXPRESS INC.FABRICANTS DE BOlTES DE CAMIONS BEL INC.BEL TRUCK BODIES BUILDERS INC.FARAND ET CHARTRAND INC.LA FERME AUDET INC.FERME AVICOLE CARRIER INC.FERME FILLION & FILS INC.LA FERME GIROUX LTÉE.LES FERMES WINDY HILL LTÉE.WINDY HILL FARM LTD.FILTREUR D'AIR ÉLECTRONIQUE ST-HYACINTHE INC.FOUCAULT AUTO INC.AUTOMOBILES FOUCAULT INC.H.FOURNIER INC.FOURRURES DELISKA INC.LES FRUITS DE MER RENÉ MARCHAND INC.G.B.DESIGN AND MANUFACTURING INC.DESIGN ET FABRICATION G.B.INC.CONRAD GAGNON INC.GARAGE LAURIER INC.GESTION CLAUDE BEAULIEU INC.GESTION HARBRIT LTÉE.HARBRIT HOLDINGS LTD.GESTION J.-G.BÉLIVEAU INC.GESTION J.OUELLET LTÉE.Sainte- Julie-de-Verchères.22 08 73 4846, chemin Côte Ste-Catherine, app.04 09 73 118, Montréal.16350, rue Marion, Pointe-aux-Trem- 17 08 73 bles.4224.rue Adam, Montréal.09 04 73 Drummondville.11 07 73 2085 Guy Street.Montreal.17 08 73 Sherbrooke.08 09 73 Saint-Lambert.10 07 73 Boucherville.30 08 73 371.Evelyne, Laval.06 08 73 Lachute.13 09 73 550, boulevard Guimond, Longueuil.20 09 73 Salaberry-de-Valleyfield.05 09 73 Maria.11 09 73 Lauzon.14 09 73 Saint-Lambert-de-Lauzon.30 08 73 165, rue Du Moulin, Saint-Eustache .12 07 73 Place d'Armes.Montréal 126.11 00 73 Saint-Hyacinthe.13 08 73 778, 3e Rue, Chibougamau.13 09 73 110, 6e Avenue.DaveluyviUe.01 09 73 Saint-Eustache.30 07 73 1465.rue Victoria, Saint-Lambert 27 07 73 8162 Devonshire.Montreal.30 07 73 Sainte-Marie.28 08 73 25, rue Brodeur, Dorion.17 07 73 146, Notre-Dame, Drummondville.13 09 73 5660 Smart, Montréal.24 08 73 66-3e Rang, Saint-Cyrille.13 09 73 700, boulevard St-Joseph, Drummond- Il 09 73 ville. 5850 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 18, 1978, Vol.105, No.U Nom / Name GESTION ROMSTAN INCORPORÉE.ROM STAN HOLDINGS INCORPORATED GIFT BOX LAVAL LTD.LA BOÎTE DE CADEAU DE LAVAL LTÉE GINAN INC.GODIN & CHARBONNEAUINC.GROSSISTES EN VIANDE ET EN NOURRITURE G.D.N INC.G.D.N.MEAT & FOOD WHOLESALERS INC.HABITEL DE LA MAURICIE INC.HELPETINC.LES HÔTELLERIES J.G.INC.LES IMMEUBLES BARNACO INC.IMMEUBLES RATIONNEL INC.LES IMMEUBLES T.T.P.INC.LES IMPORTATIONS EL MONTE LTÉE.IMPREGILO & SPINO LTÉE.IMPREGILO * SPINO LTD.LES INDUSTRIES GOTHAM INC.GOTHAM INDUSTRIES INC.LES INDUSTRIES J.A.L.LTÉE.LES INDUSTRIES RAMENA INC.RAMENA INDUSTRIES INC.LES INDUSTRIES S.C.U.(QUÉBEC) LIMITÉE.S.C.U.INDUSTRIES (QUÉBEC) LIMITED LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DIAMENT INC.DIAMENT ELECTRIC INC.LES INVESTISSEMENTS GROY LTÉE.GROY INVESTMENTS LTD.IABERO.INC.R.LAÇASSE & FILS INC.LACHINE TRUCK & TRAILER CENTRE INC.CENTRE DE CAMION * REMORQUE DE LACHINE INC.LAGANIÈRE, POULIN, LEMARIER & ASSOCIÉS INC.MARCEL LAVOIE, CONTRACTEURINC.LÉO PAUL LEDOUX MAGOG INC.CLAUDE LÉTOURNEAU INC.JOHN LEWIS INDUSTRIES LTD.INDUSTRIES JOHN LEWIS LTÉE LIBRAIRIE ANDROGYNIE LTÉE.ANDROGYNY BOOK STORE LTD.LIBRAIRIE LE BOUDOIR INC.Incorporation Siège social / Head Office Place d'Armes, Montréal 126.05 09 73 Les Galleries 2000, Boulevard St-Mar- 19 09 73 tin, Laval.785, boulevard Ducharmc, La Tuque.28 08 73 30, rue Maurice.Saint-François, Laval 30 08 73 4581 Jeanne-Mance Street, Montreal.12 09 73 Shawinigan.14 09 73 6301 Pie IX Boulevard, Montreal .00 09 73 Mont-Rolland.10 09 73 3365, Montpetit, Sainte-Foy.10 09 73 Montréal.30 07 73 71,rueSt-Pierre, suite 412, Québec.17 08 73 1240.Beaujeu, Longueuil.07 08 73 Montréal.10 09 73 231 René Robert Street,Sainte-Thérèse 21 08 73 Cabano.04 09 73 2320NantelStreet,Saint-Laurent.13 08 73 Montreal.23 08 73 4860 Plamondon, Apt.9, Montréal.19 06 73 5865, rue Verlaine, Brossard.14 09 73 4000.boulevard du Jardin, Orsainville.07 00 73 1735, rue Sherbrooke, Magog.21 08 73 4280 Joseph Dubreuil, Lachine.07 09 73 10, rue Metcalfe, Sherbrooke.30 07 73 111, rue Yves, Saint-Eustache.18 07 73 160, rue Sherbrooke, Magog.27 08 73 3061, rue Bonneville, Longueuil.31 08 73 10300 Ray Lawson Boulevard, Mont- 18 09 73 real.Montréal.07 09 73 Mont-Royal.14 09 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105- année, n° Il 5851 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date LOCATION DE CAMION LE CAMIONNEUR INC.TRUCKER TRUCK RENTAL INC.LOCATION STE-MARTIN E INC.STE-MARTINE RENTAL INC.LOISIRS BOUCHER-BORDELEAU INC.M.C.M.IMPORT EXPORT LTD.LES IMPORTATIONS EXPORTATIONS M.C.M.LTÉE.B.MACKASEY 4 ASSOCIÉS LTÉE.B.MACKASEY & ASSOCIATES LTD.LES MAGASINS HARTS (SHERBROOKE) INC.HARTS DEPARTMENT STORES (SHERBROOKE) INC.LES MAGASINS LANDRY (HAVRE-ST-PIERRE) LTÉE.MAINTENANCE ABITIBI INC.MAISON SIMONE INC.LES MAISONS MOBILES G.H.ROY INC.MAISONS MOBILES MINTO LTÉE.MINTO MOBILE HOMES LTD.MANUFACTURIERS DE MOULES 4 MATRICES SIRIUS INC.SIRIUS MOLD & DIE MANUFACTURING INC.MARINE BOUDREAULT CHICOUTIMI INC.BOUDREAULT MARINE CHICOUTIMI INC.L.MARTIN ET FILS INC.METALSPEC INC.LES MEUBLES ANDRÉ D.LEGAULT LTÉE.ANDRÉ D.LEGAULT FURNITURE LTD.MEUBLES ET DECORS MIRAGE (LAVAL) INC.MIRAGE FURNITURE AND DECOR (LAVAL) INC.LES MEUBLES HÉROS INC.M ILOT ET FRÈRES INC.MIRLAC INC.MOTEL HARRIS INC.MOTEL OSCAR INC.OSCAR MOTEL INC.SÏÔTEL VALENTINE LTÉE.VALENTINE MOTEL LTD.MOTEURS CHÀTEAUGUAY INC.CHÂTEAUGUAY MOTORS INC.MULTIDICK INC.OPTIQUE MONARCH (QUÉBEC) INC.MONARCH OPTICAL (QUÉBEC) INC PAQUETTE 4 LEBRUN INC.Longueuil.01 08 73 Sainte-Martine.16 08 73 Senneterre.04 2396 Châteauguay, Montréal.05 09 73 09 73 1155 Dorchester Boulevard West.Suite 3406, Montreal 102.30 08 73 Montréal.07 08 73 Havre-Saint-Pierre.10 09 73 Senneterre.28 03 73 3916, boulevard Samson, Laval.10 09 73 Saint-Vallier.23 05 73 Montréal.08 08 73 Rawdon.31 08 73 Chicoutimi.06 09 73 Rivière-du-Loup.04 09 73 101, du Béarn, Saint-Lambert.25 07 73 207 Beaubien Street East, Montreal.17 08 73 4690 Sources Boulevard.Dollard-des- 04 09 73 Ormeaux.3738, Masson, Laval.\t04\t07\t73 \t17\t08\t73 \t14\t09\t73 576, rue Champlain, Saint-Jean.\t10\t00\t73 1100.boulevard Taschereau, Lemoyne.\t17\t09\t73 18, rue Jolicoeur, app.3, VictoriaviUe.05 09 73 83 St-Jean-Baptiste Street, Château- 20 08 73 guay.3874A, rue Lesage, Verdun.21 06 73 21 08 73 1010 St.Catherine Street West.Suite 1005, Montreal 110.11839, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord.05 09 73 5852 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.il Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date PARQUETAGE ET TUILE HENRY INC.HENRY FLOORING AND TILE INC.PÂTISSERIE LA LORRAINE INC.PAUSE CAFÉ DE DRUMMONDVILLE INC.PELPER INC.LES PÉTROLES DE LA MAURICIE LTÉE.PHOTO LABRADOR INC.PIÈCES D'AUTO ASBESTOS INC.ASBESTOS AUTO SUPPLY INC.PIÈCES D'AUTOS ET ACCESSOIRES ST-MARTIN INC.ST-MARTIN AUTOS PARTS AND ACCESSORIES INC.LES PIÈCES D'AUTOS F.G.M.INC.PIÈCES USAGÉES D'AUTOMOBILES KENNEDY INC.PICALCO INC.PLACE VEVE INC.VEVE'S PLACE INC.LES PLACEMENTS BOISVERT INC.LES PLACEMENTS DUVERE INC.LES PLACEMENTS DUYAN (QUÉBEC) LTÉE.DUYAN INVESTMENTS (QUÉBEC) LTD.PLACEMENTS GILLES VIEL INC.LES PLACEMENTS HEROPO LTÉE.GILLES POUPART INC.LES PRODUCTIONS COMI INC.PRODUCTIONS OPUS INC.PRODUITS MARLYN LTÉE.MARLYN PRODUCTS LTD.PROGRESS FARMS LTD.LES FERMES PROGRESS LTÉE.LES PROMOTEURS ARTISTIQUES CHAMAR LTÉE.CHAMAR ART PROMOTERS LTD.LES PROMOTIONS F B INC.LES PROMOTIONS V-M LAVAL INC.LES PROPRIÉTÉS ST-ÉDOUARD INC.PUBLICATIONS DUMONT (1973) INC.PUBLICATIONS LE NORDISTE INC.QUATRAX INC.RADIO D'AUTO DE QUÉBEC INC.RAISINS DE CALIFORNIE LTÉE.CALIFORNIA GRAPES LTD.5477 Victoria Avenue, Montreal.16 08 73 4596, rue Ste-Catherine est.Montréal.12 07 73 Drummondville.04 09 73 Montreal.04 09 73 Shawinigan.04 09 73 355.rue Joliette.Sept-Iles.11 09 73 265, boulevard St-Luc, Asbestos.17 07 73 12364.rue Olivier, Montréal 389.29 08 73 Route Kennedy, Scott-Jonction, Dor- 07 09 73 Chester, Beauce.Saint-Louk-de-Pintendre.08 08 73 Sept-Iles.02 08 73 Montréal.17 07 73 432, boulevard Manseau, Joliette.18 09 73 2205, rue St-Philippe, Troie-Rivières.17 07 73 625 President Kennedy Avenue, 10 09 73 Suite 903, Montréal.8485, rue Trudel.Charlesbourg.28 08 73 Chicoutimi.06 09 73 10619, rue J.J.Gagnier, Montréal 367.10 08 73 1050, Condé, Laval.07 09 73 751 Jarry est, Montréal.13 08 73 835, rue Sauriol, Laval.20 07 73 857 Bertrand Street, Saint-Laurent.05 09 73 1235 Bélanger Street East, Montreal 04 09 73 Québec.20 08 73 Laval.14 09 73 528, Rang des Sloans, Saint-Edouard 14 09 73 3136.boulevard Lasalle, Verdun.20 09 73 Senneterre.04 09 73 7301, boulevard Sauvé, Laval-Ouest 13 08 73 2000, Sansfaçon.Giffard.02 08 73 5450 St.Patrick Street, Montreal 205.28 08 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n\" il 5853 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date RELIURE COMMERCIALE LAVAL INC.LAVAL TRADE BINDERY INC.REMBOURRAGE SUPÉRIEUR LTÉE.SUPERIOR UPHOLSTERING LTD.REMORQUACE & SURVOLTAGE ABLE INC.ABLE TOWING A BOOSTING INC.RÉPARATION D'AUTO L.G.(1973) INC.L.G.AUTO REPAIR (/97S) INC.RESTAURANT KIKI INC.RESTAURANT LE GRECO INC.RESTAURANT ODYSSÉE INC.ODYSSEY RESTAURANT INC.RESTAURANT PELLA INC.PELLA RESTAURANT INC.JOS.ROBITAILLE INC'.CHARLES-EUGÈNE ROUX INC.J.G.ST-CYR INC.CLAUDE SABOURIN INC.SCOUT INVESTMENT INC.LES INVESTISSEMENTS SCOUT INC.SEBAS LAVAL INC.SECURILOC INC.SERVIAM INC.SERVICE DE CAFÉ CHAMPION LTÉE.CHAMPION COFFEE SERVICE LTD.SERVICE DE SPORT G.B.H.INC.SERVICE DE TAXI AVENUE LTÉE.AVENUE TAXI SERVICE LTD.SERVICE FOREL INC.FOREL SERVICE INC.SERVICE MALTAIS PORT-CARTIER INC.MALTAIS SERVICE PORT-CARTIER INC.SERVICES DE VISITES ET DE CONGRÈS QUÉBEC INC.QUÉBEC CONVENTION AND VISITORS SERVICES INC.SOCIÉTÉ DE TRANSFORMATION SHAWINIGAN.SHAWINIGAN CONVERTING CORP.LA SOCIÉTÉ DUROPOL INC.SOMAPI INC.SORECOREINC.SPÉCIALITÉS B-PRO INC.B-PRO SPECIALTIES INC.Laval.18 09 73 195 Labelle Boulevard, Laval .13 08 73 Saint-Laurent.10 09 73 6383, rue Clark, Montréal.23 07 73 1265, rue Sherbrooke, Magog.07 06 73 467 Ogilvy Street, Montreal.04 06 73 Montréal.30 08 73 Sainte-Adèle.10 09 73 Québec.06 09 73 1425, boulevard Bécancour.Gentilly.08 08 73 Ville de Bécancour.Joliette.10 08 73 42S0, Beaubien est, Montréal.19 09 73 Route rurale numéro I, Saint-Elie- 18 07 73 d'Orford.Laval.30 08 73 1620 Duchesnay, Chambly.19 07 73 1813, Aunis.Orsainville.06 07 73 6420 Notre-Dame Street West, Mont- 20 08 73 real.Mistassini.29 08 73 5630 Burling, Verdun.05 09 73 6035, Pascal, Montréal-Nord.14 08 73 Port-Cartier.10 09 73 238.Place Neuviale.Duberger.17 07 73 Sainte-Thérèse.17 08 73 Boulevard Vachon, Sainte-Marie-de- 12 09 73 Beauce.38, rue Fraser, Lévis.10 09 73 5763, rue Déom, Montréal 251 .18 09 73 57, rue St-Louis, Saint-Georges.06 09 73 5S5I QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.Al Incorporation Nom / Name Siège social / Head Office Date SPERBER IMPORTS LTD.LES IMPORTATIONS SPERBER LTÉE.\tPlace Bonaventure, Montreal 114.\t21\t09\t78 LES SPORTS CLAUDE GERMAIN LTÉE.CLAUDE GERMAIN SPORTS LTD.\t300 Sicard Street, Sainte-Thérèse.\t11\t09\t73 SPORTS GILLES ROUSSEAU INC.\t120.rue Pontiac.Broniont.\t30\t(17\t73 GILLES ROUSSEAU SPORTS INC.\t\t\t\t SPORTS LÉANDRE VACHON INC\t\t23\t1)7\t73 LEAN DRE VACHON SPORTS INC.\t\t\t\t SPORTS VIMONT INC.\t\t24\tos\t78 STUDIO LORRAINE INC.\t\t11\t06\tn LES STUDIOS J.D.INC.\t\t(Mi\t09\t7:1 STUDIOS MOBILES P.I.C.INC.\t607, Place d'Armes, Montréal.\t29\tOS\t73 SUPERMARCHÉ J.L.DESJARDINS INC.\t1600, chemin Gascon, Terrebonne.\t28\t07\t78 \t\t17\t06\t73 TALTHE INC.\t\t22\tOH\t7:1 \t4986 Hickmore Avenue, Saint-Laurent\t80\tOS\t73 LES TENTES LEG RIS INC.\t1982 Jacques-Hertel, Côte St-Paul.Montréal.\t28\t00\tn \t.Montréal.\t10\tOS\t73 SEBEC LANDSCAPE INC.\t\t\t\t TIRANTS M.R.INC.M.R.TIE-RODS INC.\t7110, rue Beaudrière, App.8, Anjou .\tM\t08\t7.'! \tSainte-Madeleine.\t09\tos\t78 \t\t03\tH\t7.1 LES CONSTRUCTIONS DE QUALITÉ TITAN INC.\t\t\t\t \t237 - 8e Avenue Ue-Perrot\t31 L'2\t08 os\t \t10366.boulevard d'Auteuil, Montréal 367.\t\t\t73 7;i \t\t10\t08\t73 BIEN COURT EXPRESS INC.\t\t\t\t \t\tII\tDJ\t73 73 \t\t01,\t09\t \t20 Parc Woodland.Léry\t] ô\t08 09 00\t7.1 7.1 73 \t\t1 s\t\t \t\t07\t\t \t\t29\t08\t73 TRI M EC LTD.\t\t\t\t EXQUISITE KNITTING MILLS LTD.\t8400 Decarle Boulevard, Mount Royal.\t21\t08\t73 \t716 Victoria Square, Montreal\t17\t09\t78 VICTORIA SECURITIES LTD.\t\t\t\t \tSainte-Anastasie-de-Nelson\t22\t08\t73 \t\t\t\t Le directeur du service des compagnie», Pierre Desjardinb, 63909-o Pierre De6jardin6.63909-o Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n\" kl 5855 Lettres patentes (3e partie) Letters Patent (Part III) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes consti- of the Companies Act, he has granted letters patent incorpo- tuant en corporation: rating: Norn / Name Siège social / Head Office Incorporation Date L'ASSOCIATION DES BISONS DE ST-LOUIS INC.ASSOCIATION DES MAIRES DE LA MAURICIE INC.ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CANTON DE GA-MELIN (GALETTE) INC.L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC RÉJEAN, CHERTSEY.L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES, LAC CARILLON INC.HOMEOWNERS ASSOCIATION, LAC CARILLON INC.ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU LAC MÉGANTIC.ATELIERS DES MILLE-ISLES INC.CENTRE COMMUNAUTAIRE DU QUARTIER ST-ÉDOUARD DE MONTREAL.CENTRE D'ANIMATION TOURNESOL INC.CENTRE DE DÉPANNAGE BEAUHARNOIS INC.CENTRE DE DÉPANNAGE POUR PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES DE POINTE ST-CHARLES INC.CENTRE DE FRATERNITÉ UNIVERSELLE INC.CENTER OF UNIVERSAL BROTHERHOOD INC.LE CENTRE DE PLEIN AIR FAMILIAL DE GASPÉ INC.CENTRE DRAMATIQUE DU SUD DE QUÉBEC INC.CENTRE E.P.I.C.DE MÉDECINE PRÉVENTIVE ET D'ACTIVITÉ PHYSIQUE INC.CLUB AUTOS-NEIGE 8T-MAURICE.CLUB DE CAMPING LE BOHÉMIEN DU TÉMISCAMINGUE INC.CLUB DE L'ÂGE D'OR VIE NOUVELLE DE ST-PRIME.CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE QUÉBEC-CENTRE VILLE.LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE RIMOUSKI.CLUB DE SKI NAUTIQUE DE ST-HYACINTHE INC.CLUB DU CHIEN D'ARRÊT DE QUÉBEC INC.QUÉBEC POINTING DOG CLUB INC.CLUB OPTIMISTE LACHINE INC.CLUB RICHELIEU BOUCHERVILLE.Valmont.Trois-Rivières.386, boulevard Manseau.Joliette.Lac Réjeaii, Chertsey.Lac Carillon, Canton Chatam.Lac Mégantic.2, Grande Côte, Rosemère.Montréal.Montréal.51, St-Laurent, Beauharnois.Montréal.04 09 73 05 09 73 14 08 73 20 08 73 05 09 73 07 09 73 15 08 73 12 10 72 27 08 73 10 08 73 15 03 73 5e Avenue, Avenue du Lac, Valleyfield 03 08 73 Gaspé.2, rue St-Thomas.Lévis.Laval.Route rurale numéro 2, St-Maurice, Amos.Ville-Marie Saint-Prime 960, avenue Myrand.app 14, Sainte-Foy.50.10e Rue est.Rimouski.Saint-Hyacinthe.Québec.Lachine.Boucherville.19 09 73 13 09 73 22 05 73 05 09 73 02 08 73 09 08 73 22 05 73 23 07 73 14 09 73 18 09 73 13 09 73 04 09 73 5856 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.Il Incorporation Nom / Name Siège social / Head Office COMITÉ DES FÊTES DU CENTENAIRE DE SALABERRY DE VALLEYFIELD INC.\t74, rue St-Jean-Baptistc, Valleyfield.\t13\t08\t73 f OMIT!** niT fFMTRF SPORT!It* ROITV11 \\ .V ÎNC1\t\t27\t07\t73 COMMISSION SPORTIVE DE MONTR ÉAL-CONCORDIA INC.\t3302, rue Kent.Montréal.\t09\t07\t73 LA CONFRÉRIE INTER-GALACTIQUE DE LA LUMIÈRE ÉTERNELLE.THE INTER-GALACTIC BROTHERHOOD OF ETERNAL LIGHT.\t\tIS\t117\tn CORPORATION DE L'EXPO-SCIENCES DE QUÉBEC (C.E.S.Q.I\t\t06\t\"7\t73 LA CORPORATION DES LOISIRS DE ST-ÉLOI\t\t21\t08\t73 LE CORPS DE MAJORETTES LES ÉTINCELLES INC.\t52, rue Notre-Dame sud, Ville-Marie\t:si\t07\t73 FÉDÉRATION SPORTIVE MERCIER INC.\t5005, Duquesne.Montréal.\t03\t08\t73 FONDATION DFS DIPLÔMÉS DE POLYTECHNIQUE\t\t13\t09\t73 LES FRÈRES DE NOTRE DAME DE LA MISÉRICORDE DU LAC-SERGENT INC.\t\t16\t05\t73 \t\t11!)\t08\t73 LOISIRS CALIXA-LAVALLÉE.\tSainte-Théodosie-Calixa-Lavallée.\t29\t05\t73 ORCHESTRE PHILHARMONIQUE HELLÉNIQUE CANADIEN HELLENIC CANADIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA.\t987 Jean Talon Street West, Montreal\t\".'\t08\t73 LE PANTHÉON DES SPORTS AMATEURS DU QUÉBEC.THE QUÉBEC AMATEUR SPORTS PANTHEON.\tMontréal .\t06\t03\tT.i LE PARC DES LOISIRS ET DES SPORTS DE PLEIN AIR DE CHARLEVOIX INC.\t(Grand Fonds).Rivière-Malbaie\t14\t09\t73 RÉSEAU COMMUNAUTAIRE DE ST-GEORGES INC.\t\t20\t08\t73 SHERBROOKE HOSPITAL FOUNDATION.\t\t10\t06\t73 LA FONDATION DU SHERBROOKE HOSPITAL.\t\t\t\t LA SOCIÉTÉ SPORTIVE DES HAUTES LAURENTIDES INC.\t\t07\t06\tT.'i LE THÉÂTRE DU CENT NEUF INC.\tSherbrooke.\tm\t09\t73 Le directeur du service des compagnies, 63909-o Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 53909-o Director of the Companies Service.(Lettres patentes supplémentaires)\t(Supplementary letters patent) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a accordé des lettres patentes supplémentaires A:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Incorporation L.P.S./ S.L.P.Modifications Nom / Name Date Date Changes\t L'ACTION SOCIALE.LIMITÉE.03 04 40 10 09 73 Modifiant le capital / Altering the capital AL CARRIÈRE.EXTINCTEUR INC.06 08 71 20 05 73 Ancien nom / Former name: AL CARRIÈRE EXTINGUISHER INC.AL.CARRIÈRE, EXTINCTEUR INC. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n' kl 5857 Incorporation L.P.S./ SX.P.Modification! Nom / Name Date Date Changée LES ALIMENTS NASH (QUÉBEC) 09 01 62 28 08 73 Ancien nom / Former name: NASH FOODS (QUÉBEC) LTD.NASH CATERING SERVICE LTD.ANOUTCHKA DE PARIS INC.06 07 64 31 06 73 Etendant les pouvoirs / Extending the power! LES ARTISANS DU MEUBLE QUÉBÉCOIS INC.16 02 68 31 08 73 Etendant les pouvoirs / Extending the powers ATELIER DE PNEUS LEVIS INC.25 02 60 13 08 73 Modifiant les dispositions des lettres pa- LÉVIS TIRE SHOPING tentes / Amending the provisions of the letters patent ALBERT BACMAN LUMBER CO.LTD.02 10 56 20 07 73 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Modifying certain provisions of the letters patent BRASSERIE PARENT LIMITÉE.10 09 69 24 09 73 Ancien nom / Former name: TAVERNE PARENT LTÉE CHAMCO COMPANY LTD.23 01 67 08 05 73 Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters patent PAUL-E.CHARBONNEAU.INC.28 01 65 04 09 73 Etendant les pouvoirs/ Extending the pow- en CHICOUTIMI CHRYSLER PLYMOUTH LTÉE.06 02 68 17 08 73 Ancien nom / Former name: CHICOUTLMI CHRYSLER LTÉE CLUB DE CHASSE ST-SÉBASTIEN INC.24 11 72 16 07 73 Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers CLUB D.'ÉQUITATION ET DE TIR À L'ARC ST- 24 11 72 17 07 73 Ancien nom / Former name: SÉBASTIEN INC.CLUB DE CHASSE ST-SÉBASTIEN INC.LA COMPAGNIE DES MAÎTRES-ARTISANS DU 28 09 70 06 06 73 Ancien nom / Former name: VIEUX LONGUEUIL LIMITÉE LES ATELIERS DU VIEUX LON- GUEUIL LTÉE CONSTRUCTIONS EN TÉLÉCOMMUNICATION 06 08 69 10 09 73 Ancien nom / Former name: A.R.DE SHERBROOKE INC.RENÉ ST-PIERRE (WINDSOR) INC- G.R.CYR INC.28 03 63 05 09 73 Ancien nom / Former name: J.M.D.CYR INC.DPH INC.11 12 61 28 08 73 Modifiant le capital / Altering the capital DAVRIL Se ASSOCIATES LTD.26 08 71 05 09 73 Modifiant les pouvoirs/Modifying the powers DAVRIL & ASSOCIÉS LTÉE ÉCOLE MONT SAINT-ANTOINE.03 12 63 28 06 73 Modifiant la valeur des biens immobiliers / Modifying the value of immoveable property F.C.M.LTÉE.30 06 70 29 08 73 Modifiant le capital / Altering the capital F.C.M.LTD.GALT EQUIPMENT LTD.02 11 60 31 08 73 1 ) modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent GESTION OPTIMUM INC.10 08 71 06 09 73 Modifiant le capital / Altering the capital OPTIMUM HOLDINGS INC.LES HÉLICOPTÈRES TRANS-QUÉBEC LIMI- 21 02 69 02 08 73 1) Modifiant le capital / Altering the capital TÉE 2) Modifiant les pouvoirs / Modifying the TRANS-QUÉBEC HELICOPTERS LIMITED powerê 5S-.S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.106, No.jl Nom / Namr Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modification e Change» INSTITUT ROLAND SAUCIER.11 12 69 04 07 73 KAYBEL INC.16 Ancien nom / Former name: CENTRE DE PSYCHIATRIE SOCIALE DU SAGUENAY 09 71 23 08 73 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant les dispositions des lettres patentes/ Amending the provisions of the letters patent KEWAGAMA GOLD MINES (QUÉBEC) LIMITED 21 08 37 20 08 73 1 ) Ancien nom / Former name: KEWAGAM A GOLD MINES (QUÉBEC) LIMITED (No personal liability) 2) Convertissant la compagnie en compa- gnie régie par la première partie de la Loi des compagnies / Conxerting the company into a company governed by part I of the Companies Act 3) Modifiant le capital / Altering the capital 4) Modifiant certaines dispositions des let- tres patentes / A mending certain provisions of the letters patent LORGADAN LTD.24 08 66 24 08 73 Modifiant le capital / Altering the capital MAGASIN CONTINENTAL (AMQUI) LTÉE.27 09 72 07 08 73 Modifiant le capital / Altering the capital CONTINENTAL STORE (AMQUI) LTD.MAXI SERVICE CANADA INC.24 09 70 27 08 73 1) Ancien nom / Former name: MAXI SERVICE LAVIOLETTE INC 2) Modifiant le capital / Altering the capital 3) Etendant les pouvoirs / Extending the pe- ers 4'; Modifiant certaines dispositions des lettres patentes/ A mending certain provisions of the letters patent MERSON TIRE LTD .09 03 70 29 08 73 Modifiant certaines dispositions des lettres (latentes / A mending certain provisions of the letters patent MONTLYN ENTERPRISES LTD LES ENTREPRISES MONTLYN LTÉE 01 09 71 31 05 73 Ancien nom / Former name: ¦IOC ELY N GUEVREMONT ENTERPRISES LTD.LES ENTREPRISES JOCELYN GUEVREMONT LTÉE PAVILLON- DU PARC INC.02 01 70 22 08 73 Modifiant la valeur des biens immobiliers/ Modifying the raine of immoveable property PFI'/ER COMPANY LTD.28 12 72 28 06 73 Modifiant le capital / Altering the capital LA COMPAGNIE PFIZER LTÉE MAURICE POLLACK REALTY COMPAN Y LI- 04 02 29 06 08 73 Modifiant la capital / Altering fkt contai MITED PHECICO LTÉE.16 12 68 04 09 73 1) modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / A mending certain provisions of the letters patent LE RANCH MASSAWIPPI INC.BERN ICE SE I DM AN INVESTMENT LTD.LES INVESTISSEMENTS BERNICESEIDMAN LTÉE LE SERVICE D'ADMINISTRATION CHAM-PLAIN INC.SERVICE DE PNEUS C.T.R.LTÉE.C.T.R.TIRE SERVICE LTD.20 12 61 22 08 73 Modifiant le capital / Altering the capital OS 12 66 03 07 73 Ancien nom / Former name: WILLIAM BERGER (1966) LTD.25 08 72 27 07 73 Modifiant le capital/ Altering the capital 23 12 72 27 07 73 Modifiant le capital / Altering the capital GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° Al 5859 , \u201e Incorporation L.P.S./ SX.P.Modification» Nom / Name Date Date Change» SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS LTÉE.01 09 61 22 08 73 Modifiant le capital / Altering the capital LA SOCIÉTÉ R.A.M.INC.21 07 69 27 08 73 Etendant les pouvoirs/ Extending the pow.R.A.M.CORPORATION INC.ers SUD LOCATION INC.08 07 66 06 08 73 Etendant les pouvoirs / Extending the pou- SO VTHLEA SING INC.er» TAPIS ROUGE, AÉRO-SERVICE INC.22 04 64 27 09 73 Modifiant certaines dispositions des let- RED CARPET AERO-SERVICES INC.très patentes / Amending certain provi- sions of the letters patent TOURS ET VOYAGES INTERCONTINENTAL, 26 04 71 07 09 73 Ancien nom / Former name: INC.TRANSCONTINENTAL TOURS d INTERCONTINENTAL TOURS AND VOYAGES.TRA VEL SERVICE INC.INC.TRANSPORT MARCEL ET RENÉ INC.21 10 60 13 08 73 Ancien nom / Former name: \u201e,, cc-r.\u201e MALO TRANSPORT INC.WHISSELL INC.30 07 64 10 09 73 Etendant les pouvoirs/Extending the pou- ____ers_ Le directeur du service des compagnies.Pierre Desjardins, 53909-o Pierre Desjardinb.53909-o Director of the Companies Service.Changement de nom Change of name Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister o\"f Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Com-il a approuvé les règlements de changement de nom suivants: panies Act.he has approved the by-laws changing the name of: Nouveau nom / New name Ancien nom Former name Incorporation Date L'ASSOCIATION DES EMBOUTEILLEURS DE BOISSONS GAZEUSES DU QUÉBEC INC.QUÉBEC SOFT DRINK BOTTLERS ASSOCIATION INC.L'ASSOCIATION DES EMBOU- 15 10 70 TEILLEURS D'EAUX GAZEUSES DU QUÉBEC THE QUEBEC SOFT DRINK BOTTLERS ASSOCIATION BRADY REALTIES CORPORATION BRADY REALTIES CORPORA- 20 02 67 CORPORATION IMMOBILIÈRE BRADY TION FRANCA SHOE INC.CRÉATIONS MARIE-CLAUDE 31 03 65 CHAUSSURE FRANCA INC.INC.LES HEBDOS NATIONAUX INC.LES GRANDS HEBDOS NATIO- 10 08 73 NAUX INC.LES PROPRIÉTÉS STEINBERG LIMITÉE.STEINBERG'S PROPERTIES 25 07 56 STEINBERG'S PROPERTIES LIMITED LIMITED LES PUBLICITAIRES ASSOCIÉS LIMITÉE.ADVERTISING ASSOCIATES 12 09 53 ADVERTISING ASSOCIATES LIMITED LIMITED REVINCO CONSTRUCTION SYSTEMS INC.LOVENA INVESTMENT CO.09 06 69 LES SYSTÈMES DE CONSTRUCTION REVINCO INC.LTD.TIMBA INC.AM0S TIRE INC.28 03 73 PNEUS AMOS INC.63909-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.53909-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. 5860 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.11 Abandon de charte\tSurrender of Charter Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de la charte de:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has accepted the surrender of the charter of: Nom / Name\tIncorporation Dissolution Date Date BEAUMONT MINING CORPORATION LTD.(No personal liability).COMMODITY TRADING CO.LTD.LA COMPAGNIE DE FRUITS UNION DE SHERBROOKE LI MITÉE SHERBROOKE UNION FRUIT COMPANY.LIMITED R.DELVOYE INC.DOMAR CONSTRUCTION INC.ÉCURIE QUÉBEC INC.LES ENTREPRISES COCHAND LIMITÉE.COCHAND ENTERPRISES LIMITED LES ENTREPRISES MARIO GUINDON LIMITÉE.FLASH SCREEN PROCESS INC.HADRIS INVESTMENT CORP.HENROMAC INC.LONGUEUIL AUTO LOCATION LTÉE.LONGUEUIL AUTO LEASING LTD.MEUBLES ST-FRANÇOIS INC.ST.FRANCIS FURNITURE INC.MILNISON INVESTMENT CORP.NATIONAL TRAILER CONVOY (QUÉBEC) LTD.QUÉBEC BROADLOOM INDUSTRIES LTD.S.L.S.W.SPECIALTIES LIMITED.VINCENZO GROCERY, INC.Le directeur du service des compagnies.63909-0 Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 53909-o Director of the Companies Service.Fusion de compagnies\tAmalgamation of companies Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes autorisant la fusion de:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted letters patent authorizing the amalgamation of: Nom de la nouvelle compagnie Siège social Name of new company Head office\tFusion Nom des compagnies Amalgamation fusionnées Names of companies Date amalgamated STUDIO WILLIS INC.1095, rue St-Jean, Québec.\t20 07 73 STUDIO WILLIS INC.MARC LEGRAND MUSIQUE INC.Le directeur du service des compagnies, 53909-o Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 53909-o Director of the Companies Service.28\t(11\t54\t12\t10\t73 17\t04\t61\t05\t10\t73 12\t09\t44\t05\t10\t73 10\t09\t48\t05\t10\t73 11\t03\t69\t05\t10\t73 30\t04\t68\t12\t10\t73 02\t08\t49\t05\t10\t73 23\t04\t63\t05\t10\t73 16\t02\t62\t05\t10\t73 12\t03\t59\t05\t10\t73 09\t02\t65\t05\t10\t73 03\t07\t62\t12\t10\t73 20\t03\t57\t12\t10\t73 28\t05\t65\t06\t10\t73 30\t12\t68\t06\t11)\t73 02\t12\t66\t06\t10\t73 12\t11\t69\t06\t10\t73 24\t114\t64\t12\t10\t73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° kl 5861 Cité de Verdun Avis public est, par les présentes, donné que les propriétés ci-dessous décrites seront vendues à l'enchère publique en la Salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, dans la Cité de Verdun, au numéro 4555 avenue Verdun, MERCREDI, le VINGT-HUITIÈME jour de NOVEMBRE 1973, à ONZE heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes non payées et des intérêts mentionnés dans le relevé en plus des frais et intérêts qui ont été ou qui pourront être encourus à moins que lesdites taxes, intérêts et frais soient payés avant la vente.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées auxdits immeubles.Conditions: comptant lors de l'adjudication.City of Verdun Public notice is hereby given that the properties described hereunder will be sold by Public Auction in the Council Chamber, at the City Hall, in the City of Verdun, at 4555 Verdun Avenue, on WEDNESDAY, the TWENTY-EIGHTH day of NOVEMBER, 1973, at ELEVEN o'clock in the forenoon, for unpaid taxes, interest and costs mentioned in the statement, in addition to the costs and interest which have been or may he incurred unless said taxes, unterest and costs are paid sooner.The said sale will be made with all active and passive servitudes, apparent or occult, attached to the said properties.Terms: Cash at the time of sale.Numéro du cadastre Taxes Taxes Taxe Intérêts Nom Paroisse de Montréal mun.scol.spéc.et frais Total Name Cadastral number Mun.School Special Interest Parish of Montreal taxes taxes tax and costs Beaudry, Marcel.4678/20-21 p.Avec bâtisse dessus érigée, 324-334 avenue Egan.Bellemare, Mme Jean-Louis.4673/59 p.Avec bâtisse dessus érigée, 304-306 avenue Melrose.Berger, Albert E.4682/931 p.Avec bâtisse dessus érigée, 1346-1349 avenue Rolland.Brown, Richard M.et Kirsch Irving M.4636/38 p.Avec bâtisse dessus érigée, 178 avenue Gordon.Ciciola, Dominico et/and Ci- ciola, Emelio.3263 p.Avec bâtisse dessus érigée, 201-229 avenue River.Dubé, Mme Joseph.4561 p.Terrain vacant, avenue Galt.Gaudreau.Raoul.4452/494 p.4669/465 p.Avec bâtisse dessus érigée, 291 Première avenue.Gross, Jack.3405/585 p.Terrain vacant, rue Newmarch.How Dee Fruit Pack.Inc.3401/149 p.Avec bâtisse dessus érigée, 3624 rue Ethel.Karpman Yaphe Inc.3401/212, 213 p.Avec bâtisse dessus érigée, 3553-3557 rue Ethel.Langlois, Mme Marie-Ange.3405/192 p.Terrain vacant, rue Ethel.Lukosevicius, Dainius.4687/863 p.Avec bâtisse dessus érigée, 1643 avenue Lloyd George.Mailhot, Maurice.4670 p.Avec bâtisse dessus érigée, 1170 Troisième Avenue.Provincial Acceptance Cor- 4696 p.poration.Ilot dans le fleuve Saint-Laurent.St-Amand, Armand.4571 p.Avec bâtisse dessus érigée, 352-354 avenue de l'Eglise, Silcoff, Henry.3405/499, 500 p.Avec bâtisse dessus érigée, 721-727 avenue de l'Eglise.Wallace, Gordon F.4680/796 p.Avec bâtisse dessus érigée, 1180-1182 avenue Manning.\u2014 8 140.71 S 4.96 8 145.07 With building thereon erected, 324-334 Egan Ave.\u2014 70.08 \u2014 2.66 72.74 With building thereon erected, 304-306 Melrose Ave.253.60 \u2014 \u2014 7.25 260.85 With building thereon erected.1345-1349 Holland Ave.982.80 1,102.40 \u2014 461.13 2,546.33 With building thereon erected, 178 Gordon Ave.\u2014 \u2014 59.00 2.32 61.32 With building thereon erected.201-229 River Ave.72.75 67.50 \u2014 31.00 171.25 Vacant lot, Gait Ave.\u2014 194.40 23.56 217.96 With building thereon erected, 291 First Avenue.62.00 \u2014 \u2014 2.49 64.49 Vacant lot.Newmarch St.315.75 609.92 \u2014 203.14 1,128.81 With building thereon erected, 3624 Ethel St.210.00 397.71 \u2014 134.42 742.13 With building thereon erected, 3553-3557 Ethel St.66.75 71.10 30.51 168.36 Vacant lot, Ethel St.209.64 209.70 \u2014 92.78 512.12 With building thereon erected, 1643 Lloyd George Ave.\u2014 229.41 \u2014 8.14 237.55 With building thereon erected, 1170 Third Ave.162.00 320.64 \u2014 106.67 589.21 Islet in the St.Lawrence River.294.82 \u2014 \u2014 10.22 305.04 With building thereon erected, 352-354 Church Ave.119.26 650.42 \u2014 149.41 919.09 With building thereon erected, 721-727 Church Ave.188.96 \u2014 \u2014 7.58 196.54 With building thereon erected, 1180-1182 Manning Ave.Ventes pour taxes Sales for taxes 5862 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.il La Commission municipale du Québec, en date du 17 septembre 1973, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux desdits immeubles.Donné à Verdun, Que., ce 6e jour d'octobre 1973.Le greffier de la cité, 53885-40-2-o Jean-N.Lekebvre, o.m.a.Cité d'Alma Avis public est par les présentes donné par le soussigné, que les propriétés ci-après décrites seront vendues à l'enchère publique, au lieu ordinaire des séances du conseil, en l'hôtel de ville de la Cité d'Alma, VENDREDI, le VINGT-NEUVIÈME jour d'OCTOBRE 1973, à DIX heures, pour payer les taxes municipales et scolaires avec les intérêts et les frais, plus les frais encourus subséquemment.à moins que lesdites taxes, les intérêts et les frais ne soient payés avant la vente : Vente de propriétés pour taxes 1973.The Québec Municipal Commission has, on September 17, 1973, authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the said immoveables.Given at Verdun, Que., this 6th day of October, 1973.Jean-N.Lefebvhe, c.m.o., 53885-40-2-o City Clerk.City of Alma Public notice is hereby given by the undersigned, that the properties hereafter described will be sold by public auction at the ordinary place of the meetings of the municipal council of the city of Alma, at the Alma City Hall, on FRIDAY, the TWENTY-NINTH day of OCTOBER 1973, at TEN o'clock, for the payment of municipal and school taxes with the interest and costs, plus the costs subsequently incurred unless the said taxes, interest and costs are paid before the sale : Sale of lands for 1973 taxes.Taxes Taxes Noms et adresses des propriétaires Désignation cadastrale Munie.Scol.Total Names and addresses of proprietors Cadastral designation Munie.School lazes taxes Fédération Coop Habitat du Québec, 2030 Père Lelièvre, Québec.Fédération Coop Habitat du Québec, 2030 Père Lelièvre, Québec.Larouche Charles-Henri, 50 rue Francoeur, Aima.Thibeault, Paul-A., 1875 Davis, Aima.Tremblay, Roland.50 Durocher, Aima.2-5-6-1 -Des Lilas S 188.52 $ 11.76 8 200.2 15-A-55.Rg.VIII, Signay.2-5-6-13-Des Hydrangers 6.02 3.34 9.36 15-A-53, Rg.VIII, Signay.8-3-1-10-Francoeur 361.59 520.32 881.91 3-A-14 et 3-A-15 Rg.I, Ile d'Alma, Delisle.9-3-8-6 - Hermel 375.26 392.74 768.00 45-211 - Rg.III - Taché 9-2-4-2 - Durocher 407.71 724.24 1,131.96 1-1-16-Rg.II.Ile d'Alma Delisle.Donné à Aima, ce 17e jour de septembre 1973.ie secrétaire, 53765-40-2-o Raymond Fortin.Cité de Hull Avis est par les présentes donné par le soussigné.Greffier de la Cité, que les propriétés immobilières ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique, JEUDI, le HUITIÈME jour de NOVEMBRE 1973, à DIX heures de l'avant-midi, dans la salle de la Cour Municipale, 290.boul.St-Joseph.Hull, P.Q.à défaut de paiement des taxes municipales et/ou scolaires, ainsi que les frais encourus.Given at Alma, this 17th day of September, 1973.Raymond Fortin, 53765-40-2-o Secretary.City of Hull Notice is hereby given by the undersigned City Clerk of Hull, that the immovable properties hereunder described will he sold by public auction on THURSDAY, the EIGHTH day of NOVEMBER, 1973, at TEN o'clock in the forenoon in the Municipal Court Hall, 290 St-.Ioseph Blvd.Hull, P.Q., in default of payment of municipal and/or school taxes and costs incurred.No Rôle\tPropriétaires \u2014 Adresse\tu \u2022Il\tNuméro du cadastre\tTaxes mun.\tTaxes scol.\tFrais\tTotal Roll No.\tProprietors \u2014 Address\tp\tCadastral number\tMun.taxes\tSchool taxes\tCosts\t 30-071-02 30-133-09\tI* Châteauneuf Boisé (Société centrale d'hypothèques et de logement, Ottawa), 65-71, boul.Fournier.\t5 5\t120-59 Pt.119 Pt.05\t61,514.26 127.41\t50,740.94 433.07\t4.80 4.20\t112,259.99 664.68 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1978, 105' année, n\" Il 5863 Propriétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address fil s s Numéro du cadastre Cadastral number Taxes Mun.taxes Taxes scol.School taxes Frais Costs Guaranty Trust, rue Champlain.Grimco Amusements Ltd., rue Dussault.Fournier, Jean-Claude, (Caisse Populaire de Hull 41, rue Victoria, Hull), 77, rue St-Hyacinthe.Grand Prix Construction Ltée, (Société centrale d'hypothèques et de logement, Ottawa), 101 boul.Sacré-Coeur.Bélanger, Roland, SO, rue St-Henri.Binet, Jules, (Caisse Populaire Sacré-Coeur de Hull, 106, boul.Sacré-Coeur, Hull), 27, rue Mance.Picard, Emilien, 222, rue Laval.Poitras.Lucien (Services Financiers Avco Que.Ltée, 425, boul.St-Joseph, Hull).224, rue Laval.Bastien, Jean-Paul, 197, rue Dollard.Falardeau, Raymond, (Avco Financial Services Central Ltd., 143A.rue Principale, Hull), 254, rue Maisonneuve.Chénier, Jean-Paul (Mme Jacques Hinson, 77, rue Prud'homme, Hull), 286, rue Maisonneuve.Petit, Paul (Avco Services Central Ltd.a/s N.Duval.143.rue Principale, Hull), 294, rue Maisonneuve.Petit, Paul (Avco Services Central Ltd.a/s N.Duval, 143, rue Principale, Hull), 327, rue Champlain.Monette, Willie, 191.rue Kent.Proulx.André et Autres (Caisse Populaire Sacré-Coeur de Hull, 106, boul.Sacré-Coeur, Hull), 167, rue Dollard.Pelletier, Mme René, 320, rue Champlain.Marengère, Eva Clara (Thérèse Granger Thi-vierge, 64, rue Brady, Hull), 273, rue Notre-Dame.Thom, William, l.rueAllard.Thom, Florian, rue St-Rédempteur.Monette, Maurice (Michel Lefèbvre, 246, rue St Rédempteur, Hull), 44, rue St-Hyacinthe.Duval, Léo (Caisse Populaire.Sacré-Coeur de Hull.106, boul.Sacré-Coeur, Hull), 57, rue Charlevoix.Fournier.Wilfrid (Caisse Populaire Ste-Berna- dette de Hull, 15, rue Ste-Bernadette, Hull), 8, rue St-Hyacinthe.Legault.Maurice (Charter Credit.Corporation, 50, Place Crémazie, suite 919, Montréal), 55, Brébeuf.Mainville, Fernand (Caisse Populaire St-Joseph de Hull, 250, boul.St-Joseph, Hull), 16-18, rue St-Florent.Mainville, Fernand (Caisse Populaire St-Joseph de Hull, 250, boul.St-Joseph, Hull), 82, rue Brébeuf.Côté, Emile, 24, rue Guertin.Côté, Emile (Caisse Populaire Sacré-Coeur de Hull.106.boul.Sacré-Coeur, Hull).95, rue St- Etienne.Cyr, Roméo, Ronald, Gerald, 191, rue Laval.Deschamps, Maurice (Caisse Populaire Sacré-Coeur de Hull, 106, boul.Sacré-Coeur, Hull).127, rue St-Laurent.Courval, Georges-Henri (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria, Hull), 103, rue St-Laurent.Courval, Georges-Henri (Caisse Populaire de Hull.41, rue Victoria, Hull).101, rue St-Laurent.Boucher, Mme Vonosa, 150, rue Kent.Pt.65 45 10-12-2 5-2, 4-1-2, 217C-2, 217C-1 11-20 14-47 217F-11 217F-9 217E-17-20 Pt.S.291,302 196 Pt.N.189 Pt.N.127.41 383.09 412.92 38,648.80 284.60 204.12 675.62 747.77 493.09 673.32 190 Pt.398 Pt.S., 401 Pt.385 Pt.193 Pt.S.271 Pt.88-1 88-2 48-2 96, 68A 109-2 135,14-1 99-1 Pt.O.99-1 Pt.135-93-1 135-132 135-149 133-2 136-93A 136-93B 462 Pt.N.619.47 1,538.25 263.50 258.90 384.80 433.07 128.89 139.44 30,338.36 5S.69 64.16 180.71 268.11 163.02 260.13 215.39 181.39 392.97 127.64 480.85 220.40 501.38 270.34 196.48 446.54 198.15 83.25 113.42 129.40 63.12 122.44 98.50 107.53 232.39 79.81 135.61 160.26 192.49 190.07 99.90 4.20 4.20 4.80 4.80 4.20 4.80 4.20 4.80 4.20 4.80 4.20 4.80 4.80 4.20 2.70 1.80 4.80 2.80 2.80 3.10 2.10 2.10 4.80 3.70 3.70 3.40 4.80 2.80 4.80 3.70 3.70 4.20 5864 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.il Proprétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address 11 a* Numéro du cadastre Cadastral number Taxes mun.Mun.taxes Taxes scol.School taxes Frais Costs Dubois.Mme Gaétan, 121, rue Dollard.Antilles, Paul-Emile.117, rue Kent.Cabana, Mme Ovila, 105, rue Dollard.Cloutier, Georges, 99, rue Dollard.Lefebvre, John Maurice, (Gaétan Cyr, 150, Ca- ron, Hull), 40, rue Verdun.Barbe.Léo (Immeubles Régional Ltd., 244, boul.St-Joseph, Hull \u2014 Services Financiers Avco Que.Ltd., 143, rue Principale, Hull), 268, rue Champlain.Cyr, Huber! ; Faubert.Gilles (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria, Hull), 270-272, rue Champlain.Lavoie, Mme Gaston, 236, rue Champlain.Majeau.Urgel (Caisse Populaire Ste-Bernadelte, 15, rue Ste-Bernadette, Hull), 9, rue Garneau.Laflamme, Roger (Ronald Bélec, 30, rue Dumas, Hull \u2014 Pierre Bélanger, 25, rue Laurier, Deschênes), 24, rue Papineau.Belly, Lucien A., suce, a/s Blondin, Mme A., 30, rue Papineau.H.Gill et al (J.Roméo Groulx, 28, rue Hadley, Hull), rue Montcalm.Fournier, Yvon (Dame Gracia Pilon, 48.rue Fa-lardeau, Hull), 29, rueMorin.Boleo Inc., (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria, Hull), rueGagnon.Saucier.Rosario, 51, rue Garneau.Glazer.Michel et al (Caisse Populaire Ste-Bernadette.16, Ste-Bernadette, Hull).153.rue St-Rédempteur.Bowlby.Brian Mme.138.rue St-Rédempteur .Bigras.Gilles (Banque de Montréal, rue Principale.Hull).90, rue Charlevoix.Langlais, Paul-Emile, (Homeplan Realty Ltd., 171.rue Slater, Ottawa \u2014 Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria.Hull).167, rue Leduc.Dorsey, René (Caisse Populaire de Hull.41, tue Victoria, Hull \u2014 Maurice Miron, 166, rue Eddy, Hull), 166-168, rue Eddy.Lamoureux, Ovila (Stanley Cross, 7.boul.Hadley, Hull).96, rue Garneau.Bergeron, Thomas (Caisse Populaire de Hull.41, rue Victoria, Hull), 119-121, rue Leduc.Bédard, Fernand (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria, Hull), 32, rue Châteauguay.Duval, Léo (Bertin Leclerc, 43, rue Binet, Hull, 126, rue Laval.Sabourin, Rhéo (Marie-Rose Lapierre.144, rue Hilltop.Gatineau \u2014 Caisse Populaire Sacré-Coeur de Hull, 106, boul.Sacré-Coeur, Hull), 78.rue Kent.Les Placements Beau-Geste Ltée (DonatBoivenu 401, rue Principale.Buckingham).103-105, rue Hôte!-de-Ville.Laframboise, Jacques, In Trust, 22, rue Dollard.St-Pierre.Ronald, (Seaboard Sec.Can.Ltd., 101, rue Principale, Hull), 225-227.rue Papineau.Rcmillard.Bernard Paul.160.rue Champlain.Caveat Holdings Ltd.rue Champlain.Burger.Mme Henri.152, rue Notre-Dame.Langlois.Valère (C.G.Investments Ltd., 66 Sparks Street, Ottawa \u2014 René Lapointe et al en Fiducie, 313, chemin Montréal, Vanier), 164-166, rue Notre-Dame.Langlois, Valere (René Lapointe et al en Fiducie, 313, chemin Montréal, Vanier), 73, rue Laurier.Burger.Mme Henri (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria, Hull), 69, rue Laurier.463 Pt.518 Pt.S.499 Pt.N.504 Pt.N.314 Pt.324 Pt.S 312 Pt.N.353 Pt.N.96-89A 109-1 107-2 204-3-151-152 195-405 427 204-1-392-393 Pt.96-33-1 97-2-98-2 261-2, 297-6 143-1 140-1 184 172-1 248 769-768 97-1 99 Pt.261-2 197-2 70-1 46-2 9-2 33-2 7-1 230.58 291.72 269.55 497.46 384.13 380.67 221.87 99.49 237.78 376.04 569.63 709.31 556.86 459.66 466.05 527.42 2,047.91 710.24 253.51 596.55 1,054.98 1,401.75 1,694.73 58.27 39.19 93.65 98.13 151.57 155.84 119.67 126.00 273.86 77.01 96.43 116.19 31.40 86.20 130.06 149.84 189.62 469.42 454.71 128.18 127.29 161.98 116.60 181.06 890.72 279.89 329.06 175.16 99.62 226.83 359.32 634.36 772.76 1.80 4.20 1.80 4.20 4.80 5.40 4.80 4.20 4.20 4.80 4.20 3.70 4.20 4.80 4.20 4.20 4.20 4.80 4.80 5.40 3.20 4.80 4.80 4.80 5.40 4.80 4.20 3.70 3.40 4.20 4.20 5.40 4.80 4.80 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 octobre 1973, 105- année, n° il .-.si;:, Propriétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address I* Burger, Mme Henri (Caisse Populaire de Hull, 41.rue Victoria, Hull), 65, rue Laurier.Place Mont St-Michel Ltée (Missionnaires Oblat Marie Immaculé, 3456, ave Ontario, Montréal Sol Shabinsky in Trust a/s Glenview Realty Ottawa Ltd.170.rue Laurier.Ottawa).Place Mont St-Michel Ltée (Sol Shabinsky in Trust a/s Glenview Realty Ottawa Ltd.170, rue Laurier, Ottawa \u2014 Missionnaires Oblat Marie Immaculée.3456.ave Ontario, Montréal).121.rue Notre-Dame.R.B.Monzies Ltd., (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria.Hull \u2014 Robert Construction Co Ltd., 1512, Caberley, Ottawa), 106, rue Montcalm.Cyr, Maurice (Société de Fiducie du Québec, Cl 1180.Place d'Armes.Montréal), 93-4, rue Montcalm.Cyr.Maurice (Société de Fiducie du Québec.C.P 1180, Place d'Armes.Montréal), rue Bagot.Groulx.Mine Jeannine (Milton Cross Lumber Company Ltd.R.R.No 3.Wakefield \u2014 Club Salaberry Incorporé, 162.rue Hôtel-de-Ville.Hull).21, rue Vaudreuil.Joanette.André (Caisse Populaire St-Joseph, 250, boul.St-Joseph, Hull \u2014 Le Ministre du Revenu de la Province de Québec a/s Direction du Contentieux, 20, ave Chauveau, Que.), 9, rue Hôtel-de-Ville.Duguay, Donat.73, rue St-Jacques.Charlebois.Harvey (Gérald Pichet te.108, rue Corbeil, Hull \u2014 Mme Earl N.Noël, 8.rue Roi.Hull \u2014 Ronald Noël.8, rue Roi, Hull), 132-34, rue Wright.Motel Diplomate Fontaine Bleue Inc.(Banque Provinciale du Canada.161, rue Principale.Hull; 221 ouest, rue St-Jacques, Montréal \u2014 Banque d'Expansion Ind.350, rue King Edward, Ottawa).1.rue Montcalm, Proulx, Armand (Trust Général du Canada.120, rue Principale.Hull) 141.rue Principale.Wazik, Eyamie (Acme Restaurant Equipment Co.4100.rue Ste-Catherine.Montréal \u2014 Dame Jack Cooper a/s M.Benjamin Achbar 85, rue Principale.Hull), 123-125, rue Principale.Beauchamps.Jean-Paul (Caisse Populaire de Hull), 41, rue Victoria, Hull), 195-201, rue Principale.Forest.Mme Françoise (Caisse Populaire Ste-Bernadette, 15.rue Ste-Bernadette.Hull -Ernest Dagenais.9.rue Talbot.Hull).2.rue Taylor.Picard.Laurent (Caisse Populaire de Hull, 41 rue Victoria, Hull).36.rue Hadley.Beauchamps, Mme Clément (Pierre-Eugène Marchand.37.boul.Taché.Hull \u2014 Canada Life Ass.Co., 330 University Ave.Toronto).31, rue Hadlev.Proulx, Armand (Royal Trust Co.76 Metcalfe Street, Ottawa \u2014 Niagara Mortgage 4 Loans Co.Ltd.77 Metcalfe Street.Ottawa), 28, rue Millar.O'Neil, James (Caisse Populaire Bréboeuf, 345.boul.Alexandre Taché, Hull), 37.rue Delanau-dicre.Plouffe, Robert (Caisse Populaire Bréboeuf, 345.boul.Alexandre Taché.Hull).55.rue Coallier.Numéro du cadastre ( 'adasl r.il number 49 87-1-1 et 3 106-1 119-1.106-2 206-2.205-2 214-E.214 408-3.409-2 487 436 580-581 316-2 Pl.316-2 Pt.316-3 652-5.652-6 652-8, 654-4 292 Pt.N.E., 284 Pt.2S0-2 Pt.2-1 261-8 261-48 317-38 Pt.39 Pt.32 17-24B Pt.17-25 Taxes mun.Mun.taxes 1,508.87 2.335.25 515.08 474.32 11.467.64 1,389.40 2,568.14 741.37 1.027.63 Taxes scol.School taxes Frais Costs 545.93 159.66 4.422.77 284.76 83.94 140.47 482.80 4,970.24 5,189.75 1.174.00 209.49 321.17 385.68 135.27 216.77 4.80 2.40 2.40 5.40 2.10 2.10 4.00 4.00 1.80 5.40 3.70 4.80 5.40 4.80 4.80 4.80 2.40 5.40 3.10 4.20 .5866 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.106, No.11 No Rôle Roll No.31-056-03 31-061-15 31-062-08 31-062-09 31-071-04 31-074-10 31-091-05 31-092-18 31-093-08 31-094-18 31-095-13 31-095-15 31-090-07 31-096-02 31-101-16 31-123-03 31-123-04 31-123-42 31-131-25 31-131-30 31-133-02 31-141-01 31-141-09 Propriétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address s -a S S a Parizeau, Emile (Services Financiers Avco Que.Ltée.425, boul.St-Joseph, Place Carrier, Hull \u2014 Seaboard Sec.Can.Ltd., 101, rue Principale) 42, rue Prévost.Thibault.Rhéal (Caisse Populaire Bréboeuf, 345.boul.Alexandre Taché, Hull), 47, rue Duhamel.Filiou, Antonio (Ministère du Revenu du Québec a/s Direction du Contentieux, 20, ave Chau-veau.Que.\u2014 Béatrice Crtubise, 937, rue La-casse.Montréal), 15, rue Duhamel.Filiou.Antonio (Ministère du Revenu du Québec a/s Direction du Contentieux, 20, ave Chau-veau, Que.\u2014 Béatrice Crtubise, 937, rue La-casse.Montréal), rue Duhamel.Séguin.Mme Georges-P.68, rue Delanaudifre Bédard, Armand (Caisse Populaire Bréboeuf, 345.boul.Alexandre Taché, Hull), 15.rue St-Ursule.Barette.Emile (Niagara Mortgage & Loans Co Ltd., 77, rue Metcalfe, Ottawa), 18.rue Graham.Lunam.Edmond (Leopold Poirier.43.boul Montclair, app.2, Hull \u2014 Dame Isabelle Julien Riendeau, 43.boul.Montclair, app.2 Hull \u2014 Dame Jean-Louis Legault, 1, rue Graham, Hull), 23, boul.St-Joseph.Page, Âldège, 9.rue Châtelain.Beauchamp, Clément en fiducie.230-232.boul.Taché.Landry, Victor-Robert (Caisse Populaire de Hull, 4), rue Victoria, Hull).38, rue Viger.Landry.Victor-Robert (Caisse Populaire de Hull 41.rue Victoria, Hull).48.rue Châteaubriind Rattey.Robert (Banque Royale du Canada.100 rue Principale, Hull), 12, rue Chateaubriand Gauthier, Donald (Irène Bigras Arbic, 36, rue Delorimier, Hull).268, boul.Taché.Laroche.Gérard (Bank of Nova Scotia.Carleton University Branch, Ottawa).14, rue Place Bé- lisle.Aylmer Holdings Inc.a/s Parkway Motel, 475, rue Rideau, Ottawa \u2014 Les Dominicaines de la Trinité a/s Bernard Massé.112, rue Principale, Hull), Boul.Taché.B.M.Development Québec (Montreal Trust Co.777 Dorchester Street West.Montreal; McLean Males Common Tees, Notaries), 476, boul.Taché.Aylmer Holdings Inc.(Ronald Bélec & Cie.30.rue Dumas, Hull).27, rue St-Francois.Lepage.Jean (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria, Hull), 60, rue Taylor.Charlebois, Hervé et al (Caise Populaire St-Raymond, 53, rue St-Raymond, Hull \u2014 Dame Irène Albert, 2035, Othello, Ottawa), 32.rue Taylor.Villeneuve, Aurèle (Caisse Populaire Ste-Bernadette, 15, rue Ste-Bernadette, Hull).78.boul.St-Joseph.Glazer, Michel et al (Immeubles Niagara du Canada, 309, rue Notre-Dame, Gatineau\u2014Lucien Meunier, 50.rue Toulon.Touraine).22, rue St-Jean-Bosco Dumouchel, Mme Raymond (Charter Credit Corp., 50, Place Crémazie, suite 919.Montréal) 46 rue St-Jean-Bosco.Numéro du cadastre\tTaxes mun.\tTaxes scol.\tFrais\tTotal Cadastral number\tMun.taxes\tSchool taxes\tCosts\t 338-9, 336 Pt.\t393.55\t121.05\t6.40\t520.00 89 Pt.\t\t154.35\t4.20\t158.55 83\t850.67\t293.27\t5.40\t1.149.34 82\t97.49\t45.43\t5.40\t148.32 16-7-1 340-19, Pt.14-2-5\t410.10\t174.39 311.46\t4.20 3.70\t588.69 315.16 255-500A Pt\u201e 499A Pt.\t\t129.37\t3.10\t132.47 255-485.486 Pt.\t\t134.14\t4.30\t138.44 255-160.161 255-12.13, 14.1236 Pt., 255-1239 Pt., 1247 Pt.255-355, 356A\t241.39\t87.06 428.35 148.09\t4.20 2.80 4.20\t332.65 431.15 152.29 255-351.352 Pt.1233 Pt.255-380A.255-381A 255-30.31\t411.95\t189.38 240.01 327.39\t4.20 4.80 4.80\t193.58 244.81 744.14 10-10-12\t\t290.45\t4.80\t295.25 9-12 Pt.\t\t4,613.21\t4.80\t4,618.01 9-16-23, 16-24, 12 Pt.28 Pt,\t4,022.87\t1,387.93\t4.80\t6.415.60 9-12-3\t6,768.95\t4,545.49\t4.80\t11,319.24 410-16-1, 410-17, 297-2, 296-2 290-4, 410-27 266-24, Pt.68\t\t1,939.61 139.78\t4.80 5.40\t1,944.41 146.18 \t803.61\t326.72\t4.80\t1,135.13 255-1066.1069A.1148 Pt.\t866.06\t325.67\t6.40\t1,197.13 255-1076B, 1079, 1148B Pt.\t\t238.93\t2.10\t241.03 \t\t\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° il 5867 Propriétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address I* Taché, Jacques (Avco Financial Services Realty Ltd., 178 Bank Street, Ottawa \u2014 Caisse Populaire St-Jean-Bosco, 25, rue Booth, Hull), 16, rue Bienville.Leblanc, Florian, (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria.Hull).57, boul.St-Joseph Gauthier, Wilfrid (People's Thrift & Inv.Co.a/s Conynunity Finance Co., 48 Rideau Street, Ottawa), 23, rue Lavigne.Bulhoaw, Libunino.(Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria, Hull \u2014 Serge Ménard, 52, rue Bienville, Hull), 52, rue Bienville.Martin, Lucien.(Caisse Populaire St-Jean Bosco, 25, rue Booth, Hull), 47, rue Booth.Demeule, David, (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria, Hull), 47.rue Bienville.Thom, Florian, 63, rue Scott.Eyamie, Wagil, (Banque de Montréal, 141, rue Principale, Hull \u2014 Caisse Populaire de Hull, rue Victoria, Hull), 62, rue St-Cyr.Bigras, Gilles, (Raymond Tanghe, a/s Hélène Lapointe, 305, Thomas Pépin, BoucherVille), 56 rue St-Cyr, Rochon, Gaston, (Caisse Populaire St-Joseph de Hull, 250, boul.St-Joseph.Hull), 60, i Dupuis.Desmarais, Pierre-A.(Caisse Populaire St-Ray-mond.53.rue St-Raymond, Hull).96.boul.St-Joseph.Massie, Roger.(Clément Boulanger, 13, rue La-casse, Hull), 14, rue Lois.Duguay, Mme Fernand, 16, rue Démontigny.Monette, Aurèle, (Services Financiers Avco Que.Ltd., 425, boul.St-Joseph, Hull), 28, rue Démontigny.Auger, Mlle Berthe, 53, rue Walker.Lacroix, Albert, (Mme Albert Montpetit, 103, rue Caroh, Hull),,65, rue Jogues Desjardins, J.Alexandre.(Caisse Populaire St-Joseph, 250, boul.St-Joseph, Hull), 339, rue Laramée.Collins, Donaldo, (Caisse Populaire St-Joseph, 250, boul.St-Joseph, Hull), 14, rue Chauveau Lunam, Edward, (Gestion Hulwata, CP.574, Hull \u2014Leopold Poirier, CP.574, Hull), 44, rue Chauveau.Godin, Mme Jos Edward, (Craig Investment Ltd.50, Place Crémazie, Montréal), 281, rue Laramée.Marcil, Fernand, (Caisse Populaire St-Joseph, 250, boul.St-Joseph, Hull \u2014Caisse Populaire St-Jean Bosco, 25, rue Booth, Hull), 62, rue Rouville.Boudria, Aurèle.(Caisse Populaire St-Jean Bosco, 25, rue Booth, Hull), 61, rue Chauveau Gaudreau, Wilfrid, (Caisse Populaire St-Jean-Bosco, 25, rue Booth, Hull), 40, rue Rouville.Lalonde, Albert, (Mariange Roy Pharand, 152, rue Laval, Vanier), 37, rue Chauveau.Chartrand.Jacques, (Caisse Populaire St-Joseph, 250.boul.St-Joseph, Hull), 98, rue Delorimier.Bélair, Mme Jeannine.(Caisse Populaire St-Joseph.250, boul.St-Joseph, Hull), 86, rue Delorimier.Villeneuve, Marcel, (Caisse Populaire St-Jean Bosco, 25, rue Booth, Hull), 90, rue Delorimier.Henderson, John Jr., (Dame Aldège St-Denis, 123, rue Delorimier, Hull), 123, rue Delorimier.Numéro du cadastre Cadastral number 255-777-776 Pt.255-656 Pt., 255-657 255-636, 637 Pt.255-796, 265-797, 255-1165 Pt.255-879 Pt\u201e 880 Pt.1165 Pt.255-736, 255-737, 255-1174 Pt.255-633, 634 Pt.10-10-95 10-10-93 10-10-107 256-16.256-17 256-59 254-418 254-423 254-399 254-366 354-265 254-105 254-95 254-113 254-211 254-221 257-67 254-91 254-183 Pt.254-42 254-40, 254-39 Pt.254-164 Taxes mun.Mun.taxes 573.57 826.81 753.43 860.89 428.55 902.92 387.93 Taxes scol.School taxes 75.49 340.25 103.01 151.67 230.30 193.28 298.89 230.39 252.16 315.97 112.72 240.36 218.16 630.50 204.64 236.54 150.63 165.07 167.87 99.54 188.17 156.08 101.28 151.93 177.29 245.20 202.90 Frais Costs 5.40 4.80 4.80 5.40 4.80 4.80 2.80 6.40 4.80 4.80 4.80 4.80 4,20 4.80 5.20 3.10 4.80 4.80 5.40 4.80 6.40 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 586S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.11 No Rôle Roll No.31-208-02 32-011-01 32-015-04 32-015-30 32-015-37 32-015-43 32-021-04 32-023-01 32-025-06 32-025-12 32-027-08 32-028-16 32-031-07 32-034-17 32-035-05 32-035-15 32-036-10 32-042-08 32-045-03 32-045-28 32-052-05 32-054-04 32-054-05 32-057-01 32-057-21 Propriétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address 3iS a Beaudry, Arthur, (Niagara Mortgage and Loans Co.Ltd., 134 Sparks Street, Ottawa), 65, rue Delorimier.Filiou.Antonio, (Le Ministère du Revenu de la Province de Québec, a/s Direction du Contentieux.20, ave Chauveau, Que.\u2014 Baker Brothers Iron and Metal Co.Ltd., c/o Soloway Wright Houston McKim Killeen \u2014 Greenberg & Ciron Barristers, 170 Metcalfe St., Ottawa), 1, rue Amherst.Rocheleau.Gilles, (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria, Hull \u2014 Royal Trust Co., 76 Metcalfe Street, Ottawa,), 242-244.rue Montcalm.Moreau, Gaston, (Caisse Populaire St-Joseph de Hull.250, Boul.St-Joseph, Hull), 83, rue Lois.Maisonneuve, Roméo, (Montreal Trust Co.Montréal \u2014 Placements Craig Ltd.50, Place Crémazie, suite 607, Montréal), 69, rue Lois.Leboeuf, Paul, (Banque Toronto Dominion, Place Vincent Massey, 349, boul.St-Joseph, Hull \u2014 Aurélien Lavioïette, 57, rue Lois, Hull \u2014 René Labelle Realty Ltd.205, rue St-Patrick, Ottawa), 67, rue Lois.Ménard, Marcel, (Caisse Populaire St-Joseph de Hull, 250, boul.St-Joseph, Hull), 22, rue Tas-chereau.Simard, J.Conrad.209.boul.St-Joseph.Prévost, Benoit.(Avco Financial Services Central Ltd., 101, rue Principale, Hull \u2014 Seabord Sec.Can.Ltd., 101, rue Principale, Hull), 26, rue Dalpé.Simard, J.Conrad, 209.boul.St-Joseph.Davis, Harold, (Caisse Populaire St-Joseph.250.boul.St-Joseph, Hull), 66, rue Berri Pelland, Germain, 147, boul.St-Joseph.Hamcl, Antonio, (Caisse Populaire St-Joseph de Hull, 250, boul.St-Joseph.Hull), 84.rue Davies Latulipe.Bernard.(Caisse Populaire St-Rédempteur de Hull.170 rue St-Laurent.Hull \u2014 Dame Philippe Duval, 47, rue Nicolet, Hull).77-79, rue Amherst.Régimbald, Damase, (Caisse Populaire Ste-Bernadette, 15, rue Ste-Bernadette, Hull \u2014 Dame Georgiana Dubé-Viau, 34, rue Dufferin, Hull), 34, rue Dufferin.Belley, Mme Roland et at, (Stanley Cross, 7, rue Hadley, Hull), 65, rue Démontigny.Henri, Germain (Caisse Populaire du Lac des Fées.65, boul.Moussette.Hull), 60.rue Davies.Strasbourg, Roland, (Caisse Populaire St-Joseph, 250, boul.St-Joseph, Hull), 134, rue Amherst.DeSousa, Manuel.(Caisse Populaire St-Rédempteur, 170, rue St-Laurent, Hull), 320, rue Laramée.Artish, William, (Avco Finance Que.Ltd.81, rue O'Connor, Ottawa), 23, rue Richelieu, Larose, Théodore (Royal Trust Co., 76, rue Metcalfe, Ottawa \u2014 Union Financière Ltée, 1749, ave Carling, Ottawa), 20, rue Bisson, Petrucci, Pierre Gabin (Caisse Populaire St-Rédempteur.170.rue St-Laurent, Hull \u2014 Dame Francine Lefebvre-Landry, 600, rue Principale, Gatineau), 170, rue Amherst, Strasbourg, Mme Edouard, 174, rue Amherst.Glazer.Michel (Caisse Populaire St7Raymond, 53, rue St-Raymond, Hull), 360, rue Laramée.Vachon, Roger (Seaboard Sec.Can.Ltd., 101, rue Principale, Hull), 51, rue Labelle.Numéro du cadastre Cadastral number 254-22 250-55, 56, 57 257-8A, 257-9A 250-8 251-7, 21 257-15 247-570 247-559 247-645 Pt\u201e 249-3 247-662 Pt., 254-336 Pt.254-317, 318, 319 247-164 247-43 247-581 Pt, 247-588 247-32 247-398.247-486 Pt.254-273,272B 247-101, 102A 247-88, 247-89 Pt.8-270 247-409.247-410.247-488 Pt.247-411.412, 8-27 254 Pt,.346.247 Pl., 798 Pt., 628 247-430, Pt.481 Taxes mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal \t215.53\t4.80\t220.33 507.48\t144.99\t5^40\t657.87 \t613.91\t5.40\t619.31 \t104.08\t4.80\t108.88 \t159.24\t4.80\t164.04 436.87\t147.41\t6.00\t590.28 \t322.57\t4.80\t327.37 455.75\t1,024.91 228.49\t4.20 5.40\t1,029.11 689.64 \t272.96 152.61\t4.20 4.80\t277.16 157.41 1,379.45\t1,338.96\t4.20\t2,722.61 \t128.00\t4.80\t132.86 \t165.09\t5.40\t170.49 \t159.20\t6.40\t164.60 \t264.29\t4.80\t269.09 \t147.31\t4.80\t152.11 \t154.31\t4.80\t159.11 582.50\t219.55\t4.80\t806.85 \t196.31\t4.80\t201.11 713.56\t203.20\t5.40\t922.22 \t156.38\t5.40\t160.78 552.64\t123.78\t4.20\t680.62 360.14\t90.88\t4.80\t455.82 \t198.94\t3.10\t202.04 \t\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° il 5869 Propriétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address Numéro du cadastre Cadastral number Taxes mun.Mun.taxes Taxes scol.School taxes Frais Costs Vachon, Roger (Seaboard Sec.Can.Ltd., 101, rue Principale, Hull), 49, rue Labelle.Wooford.Charles (Dr.Paul-Emile Labelle, 24, boul.Montclair, Hull \u2014 Crescent Finance Co.Ltd., 143A, rue Principale.Hull \u2014Adeline Mainville-Godin, 127, rue Charlevoix, Hull \u2014 Stanley Cross, 7, rue Hadley, Hull \u2014 Ministre du Revenu National du Canada, Sa Majesté La Reine, P.Que.), 39, rue Labelle.Wooford, Charles (Stanley Cross, 7, rue Hadley Hull \u2014 Paul-Emile Labelle, 24, boul.Montclair, Hull \u2014 Crescent Fin.Co.Ltd., 143A, rue Principale.Hull), 37, rue Labelle.Léonard, Roméo (Maurice Charbonneau, 9, rue Lambert, Hull), 13, rue Rouleau.Roger, Gilles, 25, rue Dumas.Tessier Realties Ltée (Charter Credit Corp., 50, Place Crémazie, suite 919, Montréal \u2014 Caisse Populaire St-Joseph, 250, boul.St-Joseph, Hull), 121, rue Lois.Mirage Investments Ltée (Banque Canadienne Nationale, 22, rue St-Louis, Pte-Gatineau), 236, boul.St-Joseph.Legault, Pierre (Caisse Populaire St-Raymond 53.rue St-Ravmond, Hull), 97-103.rue Lois.Glace Crystal Ltée (André Bélanger, 1815.chemin Montréal, Ottawa \u2014 Charter Credit Corp.50, Place Crémazie.suite 919.Montréal \u2014 Aldège Cahier, C.P.72, Hull), 10.rue Amherst Richer.Aurèle (Caisse Populaire St-Joseph.250.boul.St-Joseph, Hull), 82, rue Nicolet.H.Blackburn Co.Ltd.(Société de Fiducie du Que., CP.1180, Station Place d'Armes, Mont-tréal).15.rue Jeanne-D'Arc.Daly, Louis, 71, rue Nicolet.Amyot, Charles-E., 40, rue Sherbrooke.Denis.Roland (Caisse Populaire St-Joseph.250 boul.St-Joseph, Hull), 45, rue Nicolet.Morin, Aurèle (Caisse Populaire St-Joseph, 250 boul.St-Joseph, Hull), 38, rue Dumas.Labelle, Avila (Caisse Populaire St-Joseph, 250 boul.St-Joseph, Hull), 42, rue Dumas.Bouchard.André (Caisse Populaire St-Joseph 250, boul.St-Joseph, Hull), 47, rue Dumas.Desmarais, Pierre et al (Caisse Populaire St-Joseph, 250, boul.St-Joseph, Hull), 253.boul St-Joseph.Monette, André (Caisse Populaire St-Joseph, 250 boul.St-Joseph, Hull \u2014 Jean-Claude Lemay 180, rue Amherst, Hull), 109, rue Jeanne-D'Arc Leblanc, Florian (Caisse Populaire de Hull, 41 rue Victoria, Hull).126.rue Sherbrooke.Piché.Laurent (Caisse Populaire St-Joseph, 250 boul.St-Joseph.Hull), 141, rue Nicolet.Robert, Conrad, 82, rue Sherbrooke.Villeneuve, Emile (Fidelity Finance Corp., 4661 Van Horne, suite 3, Montréal), 92, rue Dumas Tremblay, Jules (Caisse Populaire St-Raymond 53, rue St-Raymond, Hull), 85, rue Sherbrooke St-Cyr, Jean (Guarantee Trust Co.Canada, 114 rue Principale, Hull).168, rue Nicolet.Goudie.Bertyle (Royal Trust Co., 76.rue Metcalfe, Ottawa), 162, rue Sherbrooke.Lafleur, Roland, 160, rue Dumas.247-429, Pt.481 247-624 247 Pt.623 8-60 211B-2, 230B 250 Pt.40 260-31 250-22 250 Pt.59 246-344 246-741 246-207 246-Pt.222.245-Pt.103 246-219 245-60, 245-61 245-117 Pt.245-56, 57, Pt.117 245-8 248-181.248-180 246-404, 246-403, 246-622 Pt.246-184, 246-185 246-262 246-637 Pt.618 245-34 246-638, 99, 614-1, 245, 92-1, 245-128-1 246-700, 701 246-683 246-623 216.30 555.70 167.43 372.31 3,734.56 548.00 490.59 439.24 274.05 422.26 268.99 1,469.49 184.52 29.48 196.66 203.26 97.33 45.33 358.98 411.99 197.70 148.80 142.89 278.17 236.89 217.81 301.75 221.29 421.40 170.64 258.00 122.09 90.13 333.39 188.93 499.22 213.66 229.39 4.80 7.20 6.00 2.10 4.20 5.40 3.70 4.80 6.00 4.80 4.80 4.20 4.20 2.10 4.80 4.80 4.80 4.80 5.40 4.80 4.80 4.20 4.80 4.80 4.80 3.10 4.20 :,s70 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.11 Propriétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address I* Copaco Inc.(Homeplan Realty Ltd.171, rue Slater.Ottawa \u2014 Royal Trust Co., 76, rue Metcalfe, Ottawa \u2014 Real Lagassé, 707, boul.St-Joseph.Hull), 161, rue Dumas.Guèvremont, Jacques (Armand Cousineau, 1438, rue Triole.Ottawa \u2014 Caisse Populaire St-Joseph, 250, boul.St-Joseph, Hull), 66, rue Bisson.Laurin, Ferdinand (Royal Trust Co., 76, rue Metcalfe, Ottawa \u2014 Niagara Mortgage and Loans.77.rue Metcalfe.Ottawa).40.rue Bisson.Brisebois, Robert (Caisse Populaire St-Joseph.250.boul.St-Joseph.Hull \u2014 Banque Provinciale du Canada, 161, rue Principale, Hull), 341, boul.St-Joseph.Chûteauvert, Bernard (George Soriol.58, rue Lois.Hull \u2014 Banque Toronto Dominion.349, boul.St-Joseph.Place Vincent Massé, Hull), 66.rue Fontaine.Brown.Robert (Louise Descoteaux-Diotte, 60, rue Daly.app.705.Ottawa \u2014 Western Saving» and Loans Association.280.Smith Street.Winnipeg, Manitoba), 74, rue Fontaine.Robitaille.Fernand (Royal Trust Cn .76.n Metcalfe.Ottawa), 59, rue Ste-Marie.Latreille.Ernest.73, rue Fontaine.Emond.Benoit (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria.Hull), 37.rue Fontaine.Leduc, Mme P.V.et al.178, rue Berri.Alary, Maurice (Gérard Moreau Ltd.43, rue Front.Hull).33, boul.Montclair.Poitras.Lucien (Charter Credit Corp., 50, Place Crémazie.suite 919.Montréal - Services Financiers Avco Que.Ltd.426.boul.St-Joseph Hull), 91.rue Caron.Blain, Jacques (Caisse Populaire de Hull.41.rue Victoria, Hull).131.rue Ste-Marie.Charest.René (Banque Toronto Dominion.349 boul.St-Joseph.Place Vincent Massé.Hull) 113.rue Fontaine.Larivière.Paul-Emile (Banque Toronto Dominion.349, boul.St-Joseph.Place Vincent Massé, Hull).127.boul.Montclair.Déziel, Fernand (Edmond Arbique, 36.rue Delo rimier, Hull), 25, rue Fortier.Lafortune.Gilles (Caisse Populaire St-Joseph 250.boul.St-Joseph.Hull).170.rue Ste-Marie Trépanier.Mme Simone.179, rue Caron.Glazer.Richard (Caisse Populaire Pte-Gatineau.33, rue Champlain, Pte-Gatineau), 166, rue Fontaine.Savard, Ronald (Banque Toronto Dominion.349, boul.St-Joseph, Place Vincent Massé.Hull).174.rue Fontaine.La violet'e.Jacques (Gestion Hulwata Ltd., C.P.574.Hull \u2014 Isabelle Julien Riendeau.43.boul.Montclair.Hull \u2014 L'Industriel Cie Assurance-Vie, 1080.chemin St-Louis, Sillery, Que.).183.rue Ste-Marie.Rochon.Gaston (Caisse Populaire Sacré-Coeur.106.boul.Sacré-Coeur.Hull), 169.rue Ste-Marie.Payette.Paul (Caisse Populaire de Hull, 41.rue Victoria, Hull \u2014 Olympia ft York Developments, 1000 Lawrence Street West.Toronto, Ont.), 176.rue Fontaine.Numéro du cadastre Cadastral number 246-649-650 8-185-186 8-174 244 Pt.284 244-241, 244-240, 244-588 Pt.244-244 Pt.588 244-274 244-208.244-209 244-192.Pt.193 246-538 246-531.246-530 244-343.244-344 244-9S 244-50 246-583 246-498 Pt., 246-499 Pt\u201e 246-497 Pt\u201e 246-626 Pt.4-1-26 4-1-9 4-1-66 4-1-62 4-1-40 4-1-33 4-1-70 Taxes mun.Mun.taxes 970.87 l.:;'in S0 355.65 770.96 598.20 Taxes scol.School taxes 227.86 262.63 260.47 1,436.50 178.28 140 97 125.5(1 158.51 134.68 104.39 415.57 976.98 218.16 182.46 109.61 136.27 170.30 672.23 285.80 145 32 207.76 175.85 Frais Costs 3.70 5.60 5.40 5.40 5.40 5.40 4.80 4.20 3.70 4.20 4.80 5.40 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.20 4.80 4.80 6.00 4.80 3.00 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n\" il 5871 Propriétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address ce a Numéro du cadastre Cadastral number Taxes mun.Mun.taxes Taxes scol.School taxes Frais Costs 6.40 4.20 4.80 4.20 4.80 4.20 4.20 4.80 5.40 5.40 4.80 4.20 4.80 4.00 4.20 5.40 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 Toth.Julius (Gilberts St-Laurent-Leblanc.11, rue Cléroux.Hull \u2014 Banque Royale du Canada.100, rue Principale, Hull), 158, rue Jeanne-d'Are.Martel, Roland, 137.boul.Montclair.Sigouin, Robert (Caisse Populaire Lac des Fées 05, boul.Moussette.Hull).192, rue Bourque.Pinard, Yves, G0, rue Gamelin.Tanguay, Léonard \u2014 (Caisse Populaire St-Raymond, 53.rue St-Raymond, Hull), 5, rue Clé-roux.Simard, Conrad et Mme, 45.boul.Gamelin.Gervais & Masson Const.Ltée, 20.rue Bourque Saumure, Jean (Ind.Comp.Ass.-Vie, 1080.chemin St-Louis, Sillery.Que.).128.boul.Moussette.Picard, Emilien (Banque Canadienne Nationale 205, rue Principale, Hull \u2014 Caisse Populaire Sacré-Coeur.106, boul.Sacré-Coeur, Hull), 29, rue Montpetit.Bériault.Jean (Gaston Ménard, 1.rue Béland Hull) \u2014 Caisse Populaire St-Joseph, 250, boul.St-Joseph.Hull), 15.rue Montpetit.Caron.Hervé (Caisse Populaire St-Joseph.250 boul.St-Joseph.Hull).10.rue Montpetit.Bordeleau, Conrad.229.boul.Gamelin.St-Laurent.Jean R.(Caisse Populaire de Hull.41.rue Victoria.Hull).116.boul.Moussette.Marengt-re.Gérard-J.(Béatrice Morin-Bertraiid.219.rue Bell.Ottawa \u2014 Trust Général du Canada.120.rue Principale, Hull).205, boul Gamelin.Shea, Gerald.195, boul.Gamelin.Cyr.Hubert (Cécile Cloutier et al, 193, boul.Gamelin, Hull \u2014 Royal Trust Co., 76.rue Metcalfe, Ottawa), 189-191, boul.Gamelin.Laflamme, Hector (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria.Huli), 177.boul.Gamelin.Grimco Amusements Ltd.(Banque Canadienne Nationale.1155.rue Ste-Catherine est, Montréal), 440-460.boul.St-Joseph.Grimco Amusements Ltd.(Banque Canadienne Nationale.1155.rue Ste-Catherine est.Montréal).440-460.boul.St-Joseph.Grimco Amusements Co.(Banque Canadienne Nationale.1155.rue Ste-Catherine est.Montréal), 440-460.boul.St-Joseph.Poirier.Léo (C.A.C.Realty Ltd.191.rue Principale.Hull).19.rue Richer.Sabourin, Jean-Louis (Hervé Méthot.350.rue Lévis, Vanier), 9, rue Richer.Moreauit.Gaston (Caisse Populaire St-Joseph, 250, boul.St-Joseph.Hull), 14.rue Richer.Bériault, Yvan E.(Caisse Populaire Ste-Bernadette, 15, rue Ste-Bernadette, Hull), 3, rue Trudeau.Gauthier, Marcel (Société de Fiducie du Que.CP.1180, Place D'Armes.Montréal), 9, rue Trudeau.Gauthier.Marcel (Canada Life Insurance Co.330.University Ave., Toronto).20, rue Dom-pierre.Campbell, Réjean (Caisse Populaire St-Joseph.250, boul.St-Joseph.Hull), 14, rue Larose.Picard.Jean-Paul (Jeanne Laurin-Pilon, 135.boul.Gamelin, Hull).89.rue St-Raymond.Campeau, Fernand (Caisse Populaire St-Joseph.260.boul.St-Joseph, Hull), 5, rue Larose.246-740 246 Pt.588 4-88 142-20-21 Pt.142-2-52.244-513 Pt.244-514, 244-600 Pt.244-456 141-70 Pt\u201e 141-71 Pt.141-268-26.141-268-26 Pt.141-25 141-32 141-15 4-16.4-14 Pt.244 Pt.624-2 244-624-8 244-583 244-581,582 244-577, 244-578 144-5-3, 5-2 144-5-1 144 PI.-5N.S.141-205 141-255-22-5 141-255-15 142-2-5 142-2-8 142 Pt.-20-4, Pt.58 141-157 Pt.141-170 Pt.141-242 141-140 1.379.12 808.29 I 320 78 27,503.24 1,198.13 24.736 93 497.06 373.65 776.34 903.43 214.69 97.12 193.64 465.46 299.31 154.70 248.90 243.13 157.82 257.01 173.07 137.35 227.12 203.69 206.71 442.22 483.39 19,004.67 927.02 11,517.32 179.86 148.46 228.57 157.47 223.37 290.65 250.42 223.72 251.81 4.80 4.80 2.20 5872 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.11 Rang Canton de Hull / Range Hull Township No Rôle Roll No.33-012-02 33-012-21 33-012-27 33-017-24 33-022-01 33-036-10 33-038-08 33-041-34 33-043-03 33-045-04 33-053-03 33-053-29 33-054-15 33-054-20 33-065-01 33-055-10 33-061-31 33-061-36 33-071-04 33-072-18 33-072-19 33-072-20 33-072-21 33-072-26 33-072-28 Propriétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address M.Belleau, Jean (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria, Hull), 126, rue St-Raymond.Garamvolgyi.Prank (Caisse Populaire, St-Joseph 250, boul.St-Joseph, Hull).31.rue Frechette.Garamvolgyi, Frank (Caisse Populaire St-Joseph, 250.boul.St-Joseph, Hull).19.rue Frechette.Courville.Clément (Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria.Hull).19.rue Perrot.Les Constructions Pénan Ltée (Caisse de Dépota & Placement» du Que., 1200, Latour de la Bourse, Montréal), Corbeil.Pratte, Jean-Louis (Royal Trust & Niagara Mortg.76 et 77, rue Metcalfe, Ottawa \u2014 André Lavigne, 243.boul.Riel.Hull).6, rue St-Thomas.Kelly, Mme Constance, (Caisse Populaire St-Raymond.53, rue St-Ravmond.Hull).56.rue Corbeil.Sherwin.Edward.(Société centrale d'hypothc- ques & logement.Ottawa).124, rue Doucet.Maison des Enseignants de l'Oiitaouais, (Cuit,** Populaire de Hull, 41, rue Victoria.Hull), 13.rue Cholette.Légaré, Daniel, rue Cholette.Levesque.Guy et Mme.(Royal Trust Co.76._ rue Metcalfe, Ottawa).14, rue Cayer Entreprises Claude Emond.(Laurent Thauvctte.Les chenaux Vaudreuil.Co.Vaudreuil).Rue Legault.Roy.Paul, (Avco Finance Services Que.Ltd., 165.rue Sparks, Ottawa \u2014 Royal Trust 4 Niagara Mortgage, 76-77, rue Metcalfe.Ottawa).81, rue Brady.Lebel, Georges, 69, rue Brady .Girouard.Raymond.(Caisse Populaire Bt-JoMpb, 250.boul.St-Joseph, Hull), 56, rue Doucet.J.G.Bisson Const., rue Bédard.Charette.Yves.(Société Hypothèques Kinross CP.70.401 Bay Street, Toronto), 27, rue Helmer.Scott, Jean-Jules, (Caisse Populaire St-Ravmond 53, rue St-Raymond.Hull), 37, rue Helmer.Joanette, André, (Rhelco Automotive Supplies Ltd.650 Hodge, St-Laurent, Hull \u2014 Letour-neau Forest Raymond & Co.suite 700.10 est, rue St-Jacques.Montréal \u2014 Caisse Populaire St-Raymond.53.rue St-Raymond, Hull).4.rue Des Erables.Mac Leod_ & Nancliffe Const.Ltd.(Ki nros?> Mnrtg.Corp., 401 Bay Street, CP, 70, Toronto), 69 Des Erables Mac Leod & Nancliffe Const, Ltd., (Kinross Mortg.Corp., 401 Bay Street, CP.70, Toronto).67 Des Erables Mac Leod & Nancliffe Const.Ltd.(Kinross Mortg.Corp.401 Bay Street.CP.70.Toronto).65 Des Erables.Mac Leod & Nancliffe Const.Ltd., (Kinross Mortg.Corp., 401 Bay Street, CP.70, Toronto), 63 Des Erables.Mac Leod & Nancliffe Const.Ltd., (Kinross Mortg.Corp., 401 Bay Street.CP.70.Toronto), 53 Des Erables.Mac Leod & Nancliffe Const.Ltd.(Kenross Mortg.Corp.401 Bay Street, CP.70.Toronto), 49 Des Erables.6* Numéro\tTaxes\tTaxes\t\t du cadastre\tmun.\tscol.\tFrais\t \t\t\t\tTotal Cadastral\tMun.\tSchool\tCosts\t number\ttaxes\ttaxes\t\t 6B-51\t473.14\t240.72\t4.80\t718.66 6B 68\t\t207.76\t4.80\t212.56 6B 62\t\t223.72\t4.80\t228.62 6B 3\t694.47\t212.96\t4.80\t912.23 7E 133 LB\t2,370.86\t\t4.80\t2.375.66 522 6C1\t\t\t\t 6B 219\t\t244.87\t3.00\t247.87 6B-442\t\t254.93\t4.80\t259.73 7E-39\t\t180.35\t4.80\t185.15 7K 3\t1,365.04\t\t2.70\t1,368.04 7K-467\t66.44\t33.65\t4.20\t104.29 6B-323.\t\t383.94\t4.80\t388.74 6B-322 Pt.\t\t\t\t 6B 521-2\t315.94\t72.49\t4.00\t392.43 6B-354\t\t296.21\t6.40\t301.61 6B-347\t1.605.90\t595.81\t4.20\t2.205.91 6B 348 Pt.\t\t\t\t 6B-454\t\t212.62\t4.80\t217.42 6B-Pt.\t\t238.05\t4.20\t242.25 7K-169\t\t243 49\t4.80\t248.29 7K-19I\t\t233.43\t4.80\t238.23 8D-9S\t583.57\t318.74\t6.00\t908.31 8D-507-2\t199.07\t49.32\t4.80\t253.19 8D-507-3\t199.07\t49.32\t4.80\t253.19 8D-507-4\t139.27\t49.32\t4.80\t193.39 8D-507-6\t159.69\t49.32\t4.80\t213.81 8D-507-10\t200.37\t49.32\t4.80\t254.49 8D-507-12\t197.16\t49.97\t4.80\t251.93 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n\" il 5873 Propriétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address \u2022S ¦g Sincennes, Roger, (Caisse Populaire de Hull, 41 rue Victoria, Hull), 48 Desjardins.Brown, Joseph Laurier, (Royal Trust, 76, rue Metcalfe, Ottawa \u2014 Louise Descoteaux-Diot-te, 60, rue Daley, app.706.Ottawa).28 Boucher.Langford D.MacLeod Const.(Société Gazifcre de Hull Inc.365.boul.St-Joseph, Hull).66 Des Erables.Langford D.MacLeod Const., (Société Gazifcre de Hull Inc.365, boul.St-Joseph, Hull).70 Des Erables.Langford D.MacLeod Const., (Société Gazifcre de Hull Inc., 365.boul.St-Joseph.Hull).76 Des Erables.Les Entreprises Roger Pilon Inc., (Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 600, Ottawa), 78 Des Erables.Les Entreprises Roger Pilon Inc., (Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 80 Des Erables.Les Entreprises Roger Pilon Inc., (Hochelaga Homes, 77.rue Metcalfe, suite 500, Ottawa).82 Des Erables.Les Entreprises Roger Pilon Inc., (Hochelaga Homes.77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 84 Des Erables.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77.rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 86 Des Erables.Les Entreprises Roger Pilon Inc., (Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawal.88 Des Erables.Les Entreprises Roger Pilon Inc., (Hochelaga Homes, 77.rue Metcalfe, suite 600.Ottawa).28 Des Bouleaux.Les Entreprises Roger Pilon Inc., (Hochelaga Homes.77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa).30 Des Bouleaux.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes.77.rue Metcalfe, suite 500.Ottawa).32 Des Bouleaux.Les Entreprises Roger Pilon Inc., (Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa).34 Des Bouleaux.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77.rue Metcalfe, suite 500.Ottawai.36 Des Bouleaux.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes.77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 38 Des Bouleaux.Langford D.MacLeod Const., (Société Gazifcre de Hull, 365, boul.St-Joseph.Hull), 40 Des Bouleaux.Langford D.MacLeod Const., (Société Gazifcre de Hull.365.boul.St-Joseph, Hull).42 Des Bouleaux.Arvisais, Jean-Pierre, (Kinross Mortg.Corp., 401 Bay Street.Toronto), 130 Froment.Turner.Allan, (Metropolitan Trust Co., 353 Bay-Street.Toronto).33 Des Pins.L.D.MacLeod & Nancliffe Const.Ltd.(Metro-tropolitan Trust Co.353 Bay Street Toronto).31 Des Chênes.L.D.MacLeod & Nancliffe Const.Ltd.(Metropolitan Trust Co., 353 Bay Street, Toronto).33 Des Chênes.Brisson, Paui-Emile, (Metropolitan Trust Co., 353 Bay Street, Toronto), 37 Des Chênes.Numéro du cadastre Cadastral number\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal 7K-417 Pt.7K-416 7K-113\t\t296.54 234.81\t4.80 5.40\t301.34 240.21 8D-298\t324.41\t42.09\t4.80\t371.30 8D-299\t313.91\t42.74\t4.80\t361.45 SD-30tl\t270.62\t50.63\t4.80\t326.05 8D-301\t241.55\t63.12\t4.80\t309.47 8-D302\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 8D-303\t241.65\t63.12\t4.80\t309.47 8D-304\t241.55\t63.12\t4.80\t309.47 8D-305\t241.66\t63.12\t4.80\t309.47 8D-300\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 M)-2!I0\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 8D-291\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 8D-292\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 8D-293\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 8D-294\t172.10\t63.12\t4.80\t240.08 8D-295\t172.16\t63 12\t4.80\t240.08 8D-29Ï.\t251.24\t63.12\t4.80\t319.10 8D-297\t251.24\t63.12\t4.80\t319.16 8D-479\t\t225.90\t4.80\t230.70 8D-490\t\t61.16\t4.80\t65.96 8D-496\t526.64\t59.84\t4.80\t591.28 8D-497\t539.84\t65.76\t4.80\t610.40 8D-499\t\t224.91\t2.10\t227.01 5874 QUÉBEC OFFICIAI GAZETTE, October 13, 1973, Vol.106, No.11 No\t\t\tNuméro\tTaxes\tTaxes\t\t Rôle\tPropriétaires \u2014 Adresse\t\tdu cadastre\tmun.\tscol.\tFrais\tTotal Roll\tProprietors \u2014 Address\ti*\tCadastral\tMun.\tSchool\tCosts\t No.\t\t\tnumber\ttaxes\ttaxes\t\t 33-098-01\tJean Allen Const.Ltée, (Trust Général du Canada.120, rue Principale.Hull \u2014 Daniel H.McGuire in Trust, 45.rue Rideau, Ottawa),\t5\t8D-506-29\t1,039.56\t267.64\t5.40\t1,312.60 \t326 Cité des Jeunes.\t\t\t\t244.63\t2.10\t246.73 33-098-02\tJean Allen Const.Ltée, (Trust Général du Ca-\t5\t8D-506-28\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \tnada.120.rue Principale.Hull \u2014 Daniel H.McGuire in Trust.45, rue Rideau, Ottawa).\t\t\t\t\t\t \t332 Cité des Jeunes.\t\t\t\t\t6.40\t997.05 33-098-03\tJean Allen Const.Ltée.(Trust Général du Canada, 120, rue Principale, Hull \u2014 Daniel H.McGuire in Trust, 45, rue Rideau.Ottawa).\t5\t8D-506-27\t747.02\t244.63\t\t \t338 Cité des Jeunes.\t\t\t\t\t5.40\t 33-098-04\tJean Allen Const.Ltée, (Trust Général du Canada, 120, rue Principale, Hull \u2014 Daniel H.McGuire in Trust, 45.rue Rideau, Ottawa).344 Cité des Jeunes.\t5\t8D-506-26\tS51.62\t242.66\t\t1,099.68 33-098-05\tJean Allen Const.Ltée, (Trust Général du Canada, 120, rue Principale.Hull \u2014 Daniel H.McGuire in Trust, 45, rue Rideau, Ottawa).350 Cité des Jeunes.\t5\t8D-506-25\t932.54\t267.97\t5.40\t1.205.91 33-098-06\tJean Allen Const.Ltée.(Trust Général du Canada.120.rue Principale, Hull \u2014 Daniel H.McGuire in Trust, 45, rue Rideau.Ottawa).356 Cité des Jeunes.\t5\t8D-506-24\t1.035.64\t280.15\t5.40\t1.321.19 33-098-07\tJcnn Allen Const.Ltée.(Trust Général du Canada, 120.rue Principale, Hull \u2014 Daniel H.McGuire in Trust, 45, rue Rideau, Ottawa), 117 Des Erables.\t5\t815-300-23\t770.90\t277.84\t5.40\t1,054.20 33-098-08\tJean Allen Const.Ltée.(Trust Général du Canada, 120.rue Principale.Hull).115 Des Erables.\t5\t8D-506-22\t\t77.27\t2.10\t79.37 33-098-09\tHale, J.ValèrO, (Société centrale d'hypothèques et logement, chemin Montréal, Vanier).113 Des Erables.\t5\t8D-506-21\t303.38\t74 30\t4 80\t382.48 33-098-12\tJean Allen Const.Ltée, (Trust Général du Canada, 120, rue Principale, Hull), 107 Des Erables.\t5\t8D-500-18\t304.02\tOH s3\t4.80\t369.65 33-098-13\tJean Allen Const.Ltée, (Trust Général du Canada.120, rue Principale, Hull), 105 Des Des Erables.\t5\t8D-506-17\t297.83\t00.83\t4.80\t363.46 33-098-14\tPoirier, Roland, (Banque Provinciale du Canada.\t5\t8D-606-16\t300.42\t60.83\t5.40\t366.65 \tServices des Prêts Hypt., 215 ouest, rue St-\t\t\t\t\t\t \tJacques, Montréal - 79, rue Principale, Aylmer.\t\t\t\t\t\t 33-098-22\tQue.).103 Des Erables\t\t\t\t\t\t \tJean Allen Const.Ltée.(Trust Général du Ca-\t6\t8D-606-8\t\t60.83\t2.10\t62.93 33-098-23\tnada.120, rue Principale.Hull).87 Des Erables\t\t\t\t\t\t \tJean Allen Const.Ltée.(Trust Général du Ca-\t6\t8D-508-7\t309.10\tix i s;î\t4.80\t374.73 33-098-24\tnada.120, rue Principale, Hull).85 Des Erables\t\t\t\t\t\t \tJean Allen Const.Ltée, (Trust Général du Ca-\t5\t8D-506-6\t310.61\t60.83 .\t4.80\t376.24 33-098-26\tnada, 120, rue Principale, Hull), 83 Des Erables\t\t\t\t\t\t \tJean Allen Const.Ltée (Trust Général du Canada\t5\t8D-500-I\t340.05\t00.83\t4.80\t405.68 33-098-27\t120, rue Principale.Hull), #9.Des Erables.\t\t\t\t\t\t \tJean Allen Const.Ltée (Trust Général du Canada.120.rue Principale.Hull), 77.Des Erables.\t5\t8D-506-3\t299.35\t60.83\t4.80\t364.98 33-098-28\tJean Allen Const, Ltée (Trust Général du Canada.\t6\t8D-506-2\t299.35\t60.83\t4.80\t304.98 33-112-06\t120.rue Principale.Hull).75.Des Erables.\t\t\t\t\t\t \tFayne.Roger (Société centrale d'hypothèques et\t5\t8D-232-I\t342.24\t\t4.80\t347.04 \tlogement, chemin Montréal, Vanier), 32, Per-\t\t\t\t\t\t 33-112-12\tMcNally, Gordon (Société centrale d'hypothèques\t5\t8D-4I17\t\t180.10\t4.80\t190.90 \tet logement, chemin Montréal, Vanier, 44,\t\t\t\t\t\t \tPerras.\t\t\t\t\t\t 33-112-14\tDavidson, Wayne (Société centrale d'hypothèques et logement, chemin Montréal, Vanier).48, Perras.\tS\t8D-406\t\t193 99\t4.80\t198.79 33-112-31\tL.D.MacLeod & Nancliffe Const.Ltd., 152, Des Bouleaux.\t5\t8D-24I\t352.97\t09.71\t4.20\t426.88 33-113-01\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga\t5\t8D-307\t172.16\t03.12\t4.80\t240.08 \tHomes, Inc.77, rue Metcalfe, suite 500.\t\t\t\t\t\t \tOttawa).90, Des Erables.\t\t\t\t\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° 11 5875 No\t\t\tNuméro\tTaxes\tTaxes\t\t Rôle\tPropriétaires \u2014 Adresse\tS' s «\tdu cadastre\tmun.\tscol.\tFrais\tTotal Roll\tProprietors \u2014 Address\t= -s\tCadastral\tMun.\tSchool\tCosts\t No.\t\tc\tnumber\ttaxes\ttaxes\t\t 33-113-02\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, Inc., 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa).92.Des Erables.\t5\t8D-308\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 33-113-03\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes.77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa).94, Des Erables.\t5\t8D-309\t172.10\t63.12\t4.80\t240.08 33-113-04\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa).96, Des Erables.\t5\t8D-310\t232.40\t90.09\t4.80\t327.29 33-113-05\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77.rue Metcalfe, suite 500.Ottawa).106, Des Erables.\t5\t8D-31I\t171.44\t62.80\t4.80\t239.04 33-113-06\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 108.Des Erables.\t5\t8D-312\t171.44\t62.80\t4.80\t239.04 33-113-07\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77.rue Metcalfe, suite 500, Ottawa).110.Des Erables.\t5\t8D-313\t171.44\t62.80\t4.80\t239.04 33-113-08\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa\".112.Des Erables.\t5\t8D-314\t171.44\t62.80\t4.80\t239.04 33-113-09\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500.Ottawa), 114, Des Erables.\t5\t8D-315\t171.44\t62.80\t4.80\t239.04 33-113-10\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 116, Des Erables.\t5\t8D-316\t174.28\t62.80\t4.80\t242.88 33-113-11\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa).118.Des Erables.\t5\t8D-317\t140.70\t62.80\t4.80\t208.30 33-113-12\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 120.Des Erables.\t5\t8D-318\t217.70\t62.80\t4.80\t285.30 33-113-13\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes.77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 122.Des Erables.\t5\t8D-319\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 33-113-14\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 124.Des Erables.\t5\t8D-320\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 33-113-15\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 126, Des Erables.\t5\t8D-321\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 33-113-16\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77.rue Metcalfe, suite 500.Ottawa), 128.Des Erables.\t5\t8D-322\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 33-113-17\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 130.Des Erables.\t5\t8D-323\t307.84\t63.12\t4.80\t376.76 33-113-18\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500.Ottawa), 2, Des Bouleaux.\t6\t8D-277\t307.84\t63.12\t4.80\t375.76 33-113-19\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa),\t5\t8D-278\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 \t\t\t\t\t\t\t \t4, Des Bouleaux.\t\t\t\t\t\t 33-113-20\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 6, Des Bouleaux,\t5\t8D-279\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 33-113-21\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 600, Ottawa), 8, Des Bouleaux.\t5\t8D-280\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 33-113-22\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 10, Des Bouleaux.\t5\t8D-281\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 33-113-23\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 12, Des Bouleaux.\t6\t8D-282\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 33-113-24\tLes Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes.77, rue Metcalfe, suite 600, Ottawa), ] i 1 ),'.RmtloQnr\t5\t8D-283\t172.16\t63.12\t4.80\t240.08 5876 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.il No Rôle Roll No.33-113-25 33-113-26 33-113-27 33-113-28 33-113-29 33-113-30 33-114-01 33-114-02 33-114-03 33-114-04 33-114-05 33-114-06 33-114-07 33-114-08 33-114-09 33-114-10 33-114-11 33-114-12 33-114-13 33-114-30 33-114-31 33-114-32 33-114-33 Propriétaires\u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77.rue Metcalfe, suite 500, Ottawa).16, Des Bouleaux.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa).18.Des Bouleaux.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes.77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 20, Des Bouleaux.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes.77, rue Metcalfe, suite 500.Ottawai, 22.Des Bouleaux.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 24, Des Bouleaux.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Mercalfe, suite 500, Ottawa), 26.Des Bouleaux.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes.77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 366, Cité des Jeunes.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77.rue Metcalfe, suite 500, Ottawa:, 368, Cité des Jeunes.Les Entreprises JRoger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 370, Cité des Jeunes, Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes.77.rue Metcalfe, suite 600, Ottawa).372.Cité des Jeunes.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes.77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa).374.Cité des Jeunes.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa) 376, Cité des Jeunes.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes.77.rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 378, Cité des Jeunes.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 380.Cité des Jeunes.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes.77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 382, Cité des Jeunes.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), 384, Cité des Jeunes.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelagr.Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa) 209.Mont-Bleu.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa) 207, Mont-Bleu.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa) 205, Mont-Bleu.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 600, Ottawa).Des Erables.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77.rue Metcalfe, suite 500, Ottawa) Des Erables.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77.rue Metcalfe, suite 600, Ottawa) Des Erables.Les Entreprises Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77.rue Metcalfe, suite 500, Ottawa) Des Erables.G' Numéro du cadastre Cadastral number 8D-284 8D-285 8D-286 8D-287 8D-288 8D-289 8D-38 8D-39 8D-40 8D-41 8D-42 8D-43 8D-44 8D-45 8D-46 8D-47 8D-48 8D-34S 8D-349 8D-49 8D-50 8D-51 8D-62 Taxes mun.Mun.taxes 172.16 172.16 172.16 156.06 216.96 169.25 455.48 292.54 292.54 292.54 292.54 292.54 293.25 303.01 306.07 305.20 632.92 352.34 357.47 242.65 207.43 207.43 207.43 Taxes scol.School taxes 63.12 63.12 63.12 55.90 83.20 01.81 93.71 80.56 80.50 80.56 80.56 80.56 80.89 84.83 86.15 85.83 114.09 82.53 84.83 94.70 78.91 78.91 78.91 Frais Costs 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 Total GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, i,° 41 5877 Propriétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address Les Entreprise-s Roger Pilon Inc.(Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa).Des Erables.Les Entreprises Hoger Pilon Inc, (Hochelaga Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500.Ottawa), Des Erables.Les Entreprises Hoger Pilon Inc.(Hochelagn Homes, 77, rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), Des Erables.Les Entreprises Hoger Pilon Inc.(Hochelaga Homes.77.rue Metcalfe, suite 500, Ottawa), Des Erables.Benoit, Raymond (Caisse Populaire St-.Ioseph.250, boul.St-Joseph.Hull), S, Bernier.Bélanger.Roger-E.(Banque Royale du Canada.Place Cartier, boul.St-Joseph.Hull).27.Bernier.156 Le Mont-Bleu Boul.Ltée (Société centrale d'hypothèques et logement, chemin Montréal, Vanier), 29-31.rue Hinchev.156 Le Mont-Bleu Boul.Ltée (Société centrale d'hypothèques et logement, chemin Montréal.Vanier), 21-25, rue Hinchey.Larose, Raymond (Banque Toronto Dominion, 349, boul.St-Joseph, Hull), 130.boul.Mont-Bleu.150 Le Mont-Bleu Boul.Ltée.151.boul.Mont-Bleu.Chatillon, Denis (Langford D.McLeod Const.Ltd.392, boul.Cité des Jeunes.Hull).178.boul.Mont-Bleu.Petit, Guy (L.D.McLeod Const.Ltd., 392.boul.Cité des Jeunes, Hull \u2014 Banque Canadienne National, 229.boul.St-Joseph, Hull).13.rue Marcoux.St-Germain.Théodore (Trust Général du Canada.120, rue Principale.Hull), 20, rue Pelletier.MacLeod Const.(Trust Général.120.rue Principale.Hull).18 Pelletier.Bordeleau, Conrad (Banque Toronto Dominion.359.boul.St-Joseph, Hull \u2014 Can.Gen.Elex.Credit Ltd.214.King west, Toronto \u2014 L.D.MacLeod Const.392, boul.Cité des Jeunes, Hull \u2014 Thom Const.Ltd.231 ' j.rue St-Rédempteur, Hull).240 Mont-Bleu.Bordeleau, Conrad, (Banque Toronto Dominion, 359, boul.St-Joseph.Hull \u2014 L.D.MacLeod Const.392.boul.Cité des Jeunes.Hull \u2014 Can.Gen.Elex.Credit Ltd.214 King West.Toronto \u2014 Thorn Const.Ltd.2314.rue St-Rédempteur, Hull).390 Cité des Jeunes.MacLeod Const., Lemieux.Séguin, Vvon (Caisse Populaire St-Joseph,250 boni.St-Joseph, Hull), 136 Archambault.Rocheleau, Gilles.(Georges Piché, 92, rue St-Raymond, Hull).100 St-Raymond Bastien.Arthur, (Caisse Populaire St-Raymond.53, rue St-Ravmond.Hull \u2014 Seaboard Set.Can.Ltd., 178, rue Bank, Ottawa), 145 Richer Hupé.Jules, 144 Richer.Boileau, Roger, (Service Financier Avco Que.Ltd.425, boul.St-Joseph, Hull \u2014 Lorenzo LeBlanc, 2, rue Brébeuf, Hull), 147 Joffre.Sauvé, Fernand, 6 Benedict.Thom, Rhéo.rue May Thom, Rhéo, rue May.Sauvé, Vvon Mme et at, (Caisse Populaire St-Raymond, 53, rue St-Raymond, Hull), 180 Archambault.Numéro du cadastre Cadastral number 8D-53 8D-54 8D-55 8D-56 7C-50 8C-237 8C-251 Pt.250, 249 Pt.8C-255, 254, 253.252, 251 Pt.7C-8 SO-250 SC-240 Pt.-I 80-80 8C-48-2 8C-48-1 90-35 9C-36 9C-34, 8C-210-1.8C-211 573-5 5-400.401, 402, 399 Pt.5-502 5-539 5, 554 5, 310, 311 5.612 Pt.5.613 5, 350, 351 Taxes mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal 207.43\t78.91\t4.80\t291.14 207.43\t78.91\t4.80\t291.14 207.43\t78.91\t4.80\t291.14 352.46\t92.07\t4.80\t449.33 \t228.91\t4.80\t233.71 320.59\t65.10\t4.80\t396.49 5.044.60\t1.710.74\t4.80\tG.7G0.20 7,711.99\t2,591.96\t4.80\t10,308.75 \t232.72\t4.80\t237.52 9,200.09\t2,692.91\t4.20\t11.897.20 \t84.61\t4.80\t89.41 348.46\t26.31\t5.40\t380.17 \t199.91\t4.80\t204.71 \t199.91\t4.80\t204.71 \t155.73\t6.60\t102.33 \t160.80\t6.60\t167.40 \t377.14\t4.20\t381.34 \t173.42\t4.80\t178.22 604.58\t740.00\t4.80\t1,355.38 \t163.72\t5.40\t169.12 \t160.99\t4.20\t165.19 \t266.71\t2.40\t269.11 489.49\t74.40 42.32\t4.20 4.20\t568.09 46.32 944.49\t53.07 304.17\t4.20 4.80\t57.27 1,253.46 .5878 QUÉBEC OFFICIAI.0A7.F.TTF, October 13, 197.1, Vol.105, No.11 No Hole Roll No.33-164-04 33-165-13 33-166-02 33-171-04 33-174-18 33-174-22 33-181-10 33-181-11 33-181-13 33-181-14 33-181-15 33-182-13 33-184-03 33-189-05 33-201 07 33-201-08 33-201-09 33-201-10 33-211-09 33 213 2:! 33 232-04 33-251-09 33-252-05 33-252-10 33-253-02 33 21,3 (11 Propriétaires -\u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address g 5 Frechette, Lucien.(Royal Trust Co., 76.rue Metcalfe.Ottawa \u2014 Banque Provinciale du Canada.745.boul.St-Joseph.Hull - 221.rue St-Jacques.Montréal).77 Desoliviers Ernond.Jacques.(Caisse Populaire St-Joseph.250.boul.St-Joseph.Hull).54 I.\u2014.id Brunette.Camille.2 May.Hôtel le Moulin Rouge de Hull Ltée, (Banque d'Exp.Ind.800.carré Victoria, suite 4600.Montréal \u2014 Caisse Populaire de Hull, 41, rue Victoria, Hull), 615 St-Josèph.Le Diplomate Inc.(Coronation Credit Corp.Ltd., 36 Toronto St.Toronto).515 St-Joseph Le Diplomate Inc.(Coronation Crédit Corp.Ltd.36 Toronto St.Toronto), rue St-Raymond.Gauthier.Man-el.(Caisse Populaire St-Raymond.53.rue St-Raymond.Hull).15 Marquette.Gauthier.Marcel.(Cais>< Populaire St-Raymond.53.rue St-Raymond.Hull).13 Marquette.Gauthier.Marcel, (Caisse Populaire St-Raymond, 53, rue St-Raymond, Hull).9 Marquette.Gauthier.Marcel, (Caisse Populaire St-Raymond, 53.rue St-Raymond, Hull), 7 Marquette.Gauthier.Marcel, (Caisse Populaire St-Raymond.53, rue St-Raymond.Hull), 47 Mutchmore.Laflarmnc.Raymond.(Alliance Coinp.Mut.Ass.680 ouest, rue Sherbrooke.Montréal \u2014 Royal Hamel.23.rueBrodeur.Hull).4l Mutchmore.Gauthier.Liliane.6 Damien.Renaud.Albert en Fiducie.(Laurie Normand.5.rue Hotel-de-Ville.Hull).21 Dagenai>.Floury, J.Paul, (Caisse Populaire St-Joseph.250.boul.St-Joseph.Hull).040 St-Joseph Brisebois.Rolierl.Boul.St-Joseph Brisebois.Robert.Boul.St-Joseph Briseboi.-.Robert en Fiducie.Boul.St-Joseph.Hudon, Jacques Roland, (Claude LeBlaiic Ltd, 108, rue Montcalm, Hull \u2014 Trust Gén.du Canada.120.rue Principale, Hull \u2014 René Labelle Realties Ltd., 205, rue St-Patrick, Ottawa) 137.boul.Kiel.Valade, Roland, (Aimé Tassé, 6, rue Cartier, Lucerne).94 St-Onge.Guilbault.Lionel & Aimé.(Guar.Trust Co.of Can., 109.rue Bank, Ottawa\u2014 Union du Canada Ass.-Vie, 325.rue Dalhousie.Ottawa), 30 Normand.J.P.Chénier Co.Ltée.(Western Saving -\"\u2022- Attorneys for the Company.Sorrento Construction ltée Notice is hereby given that \"Sorrento Construction ltée\", will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal.Decemlier 29th, 1972.Kaufman & Posman.53931-0 Attorneys for the Company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, «° il 5889 Schafer Knitting Mills Ltd.Avis est par les présentes donné que « Schafer Knitting Mills Ltd.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social dans la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 24e jour de septembre.1973.Le secrétaire, 53930-o Pkarl Lighter.Schafer Knitting Mills Ltd.Notice is hereby given that \"Schafer Knitting Mills Ltd.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 24th day of September, 1973.Pearl Lighter, 53930-o Secretary.Superior Asbestos Ltd.Avis est par les présentes donné que « Superior Asbestos Ltd.» constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Quél>ec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 10e jour de septembre 1973.Les procureurs de la compagnie.53932-o Phillips & Vinebehg.Superior Asbestos Ltd.Notice is hereby given that \"Superior Asbestos Ltd.\" a corporation incorporated under the Companies Act anil having its head office in the City of Montreal will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dateil at Montreal, this 10th day of September, 1973.Phillips & VlNEBERO, 53932-0 Attorneys for the Company.Divers Compagnies Miscellaneous Companies Dragon Construction limitée La compagnie « Dragon Construction limitée donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Guy Gauthier.53933-0 3822-IS Dulex inc.La compagnie « Dulex inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.Le secrétaire.Jean Pelletier.53934-0 5126-G9 Grenier, Ruel & Cie inc.Grenier, Ruel & Co.Inc.La compagnie « Grenier, Ruel & Cie inc.\u2014 Grenier, Ruel & Co.Inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 9 à 7.IjC secrétaire.Pierre Jean.53935-0 5915-46 Dragon Construction limitée Notice is given that \"Dragon Construction limitée\" has increased the number of its directors from 3 to 4.53933 (Juv Gauthier, Secretary.3822-48 Dulex inc.Notice is given that \"Dulex inc.\" has changed the number of its directors from 3 to 5.Jean Pelletier.Secretary, 5126-69 53934 Grenier, Ruel & Cie inc.Grenier, Rue] & Co.Inc.Notice is given that \"Grenier, Ruel & Cie inc.\u2014 Grenier, Ruel & Co.Inc.\" has decreased the number of its directors from 9 to 7.Pierre Jean, Secretary.53935 5915-46 :,soo QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.October 13.1973.Vol.105.No.11 Marché Girardin inc.La compagnie « Marche Girardin inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Jacques Girardin.58986-0 726314 Marché Girardin inc.Notice is given that \"Marché Girardin inc.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.53936 Jacques Girardin, Secretary.726314 Sièges sociaux Head offices Minoteries Africaines inc.African Milling Inc.Avis est donné que la compagnie « Minoteries Africaines inc.\u2014 African Milling Inc.».constituée en corporation par lettres patentes en date du 28 août 1972, et ayant son bureau principal dans la ville de Montréal, a établi son siège social au numéro 1115 ouest, rue Sherbrooke, Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal.P.Q., le 20e jour de février 1973.(Sceau) 53937-0 Ixt secrétaire.Nicole Forest.Au Domaine Joly inc.La compagnie « Au Domaine Joly inc.\u2022 donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 450.rue Normandie.Sherbrooke, au numéro 195, chemin Le-mire, Fleurimont./V secrétaire, Michel Joly.53938-0 2286-70 Le Crédit Mylbcc inc.Avis est donné que la compagnie « l,e Crédit Myl-bec inc.« constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 juillet 1964, et ayant son siège social à 50 Place Crémazie.suite 1008, Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'à aujourd'hui l'a transporté à 360.rue_St-Jacques, suite 407, Montréal, Québec.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 1er jourd'aoùl 1973.(Sceau) La secrétaire, Michelle C.Uêliveau.58939-0 3371-64 Librairie Mobilex inc.La compagnie « Librairie Mobilex inc.» donne avis qu'elle a changé son siège de Saint-Léonard, au numéro 24.Croissant d'Avaugour, Laval.Le secrétaire, Louis Page.68956-0 723318 Minoteries Africaines inc.African Milling Inc.Notice is hereby given that the company \"Minoteries Africaines inc.\u2014 African Milling Inc.\", incorporated by letters patent, on the 28th day of August, 1972, and having its head office in the City of Montreal, has established its office at No.1115 Sherbrooke Streel West, Montreal.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal.Quebec, this 20th day of February.1973.(Seal) Nicole Forest, 53937-0 Secretary.Au Domaine Joly inc.Notice is given that \"Au Domaine Joly inc.\" has transferred its head office from 450 Normandie Street, Sherbrooke, to 195 Lcmire Road.Fleurimont.5393S Michel Joly, Secretary.2286-70 Le Crédit Mvlbee inc.Notice is hereby given that \"Le Crédit Mylbcc inc.» incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated July 24th, 1964, and having its head office at 50 Place Crémazie, suite 1008, Montreal, where its office was situated up to-day, has moved it to 360 St-.lamcs Street, suite 407.Montreal, Québec.From and after the date of this notice, the said office shall lie considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 1st day of August, 1973.(Seal) Michelle C.Beliveau.Secretari/.53939-0 3371-64 Librairie Mobilex inc.Notice is given that \"Librairie Mobilex inc.\" has transferred its head office from St-Léonard to 24 Croissant d'Avaugour, Laval, Louis Page, Secretary.53956 723318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973.10:,' année.«° 11 5891 Chaussures Norbero Inc.Norbero Shoes Inc.Avis est donné que la compagnie « Chaussures Norbero Inc.\u2014 Norbero Shoes Inc.», constituée en corporation par lettres patentes datées du 20 juillet 1973 a son bureau chef à St-Émile, Québec.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau chef.Signé à Montréal, ce 14 août 1973.53941-0 NOKMANII ClIEVRIEH.Chaussures Norbero Inc.Norbero Shoes Inc.Notice is given that \"Chaussures Norbero Inc.\u2014 Norbero Shoes Inc.\", incorporated by letters patent dated July 26, 1973, has its head office in St.Emile, Québec.From the date of this notice, the said office shall be considered by the company as its head office.Dated in Montreal, August 14, 1973.53941 Normand Ciieviiieh.Costain (Québec) Dec Costain (Québec) Ltd.Avis est donné que la compagnie « Costain (Québec) Ltée \u2014 Costain (Québec) Ltd.», constituée par lettres patentes datées du 13 septembre 1973 et ayant son siège social à Montréal, P.Q., a établi son bureau à suite 750.1 Place Ville Marie.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montreal, P.Q.ce 20e jour de septembre 1973./.c président, 53942-0 Ruby A.Oxneh.Costain (Québec) ltée Costain (Québec) Ltd.Notice is hereby given that \"Costain (Québec) Ltée \u2014 Costain (Québec) Ltd.\".incorporated bj letters patent dated September 13th, 1973 and having its head office in Montreal, P.Q., has established its office at Suite 750, 1 Place Ville Marie.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the Company as being its head office.(liven at Montreal, P.Q., this 20th day of September.1973.Rib y A.Oxxer, 53942-0 President.(Airly Joe's (Sherbrooke) Ltée/Ltd.Avis est par les présentes donné que « Curly Joe's (Sherbrooke) Ltée/Ltd.», constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies a étanli son siège social à 3050 boulevard Portland, dans le Centre d'Achat le Carrefour de l'Estrie, dans la ville de Sherbrooke, province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 25e jour de septembre 1973.(Sceau) Ijc secrétaire.53943-0 Sam Rubin.Curly Joe \"s (Sherbrooke) Ltd./Ltée Notice is hereby given that \"Curly Joe's (Sherbrooke) Ltd./ Ltée\", incorporated by letters patent issued under the provisions of Part I of the Companies Act, did establish its head office at 3050 Portland Boulevard, in le Carrefour de l'Estrie Shopping Centre, in the City of Sherbrooke, Province of Quebec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 25th dav of Septeml>cr, 1973.(Seal) Sam Rubin, 53943-0 Secretary.Diamond & Tucker Limited Avis est donné que la compagnie « Diamond & Tucker Limited » constituée en corporation par lettres patentes en date du 26c jour de février 1971, et ayant son siège social dans la ville de Montréal où elle avait son bureau situé à 1.carré Westmount.Chambre 386.l'a transporté à 2050.rue Mansfield.Montréal.H3A 1Y9.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté le 12e jour de septembre 1973.Le secrétaire.53945-0 Arthur Diamond.Diamond & Tucker Limited Notice is hereby given that \"Diamond & Tucker Limited\" incorporated by letters patent, on the 26th day of February, 1971.and having its head office in the City of Montreal, where its office was situated at One Westmount Square.Suite 386.has moved it to 2050 Mansfield Street.Montreal.H3A 1Y9.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated the 12th day of September, 1973.Arthur Diamond, 53945-0 Secretary. 5.S92 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, Ao.il Arthur Diamond Inc.Avis est donné que la compagnie « Arthur Diamond Inc.» constituée en corporation par lettres patentes en date du 3c jour de juillet, 1964, et ayant son siège social dans la ville de Montréal où elle avait son bureau situé à 1, carré Westmount, chambre 386.l'a transporté à 2050, rue Mansfield, Montréal, H3A 1Y9.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté le 12e jour de septembre 1973.Le président.53944-0 Akthur Diamond.Arthur Diamond Inc.Notice is hereby given that \"Arthur Diamond Inc.\" incorporated by letters patent, on the 3rd day of July, 1964, and having its head office in the City of Montreal, where its office was situated at One Westmount Square, Suite 386, has moved it to 2050 Mansfield Street, Montreal, H3A 1Y9.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated the 12th day of September, 1973.Arthur Diamond.53944-0 President.Fairfay Corporation Avis est par les présentes donné que la compagnie « Fairfay Corporation », constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies du Québec, a transféré son siège social du 1888, Dunkirk Road à ville Mont-Royal, Québec, au 165.avenue Kindersley.à ville Mont-Royal.Québec et ce à compter du 11 octobre 1973.Fait à Montréal, le 17 septembre 1973.Le secrétaire.53946 Frank Yernon.Fercour Inc.Avis est donné que la compagnie « Fercour inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 17e jour de juillet 1972, et ayant son siège social dans la ville de Sorel, a établi son bureau principal au numéro 151.de la rue du Prince.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Sorel.Québec, ce 1er jour d'août 1972.(Sceau) Le président, F.Cournoyer.53947-0 724009 Foyers CD.Inc.CD.Fire-Place Inc.Avis est donné que la compagnie « Foyers CD.inc.-CD.Fire-Place Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 19 avril 1973 et ayant son siège social à 10.707 rue London, appartement 2.Montréal-Nord, où elle avait son bureau situé jusqu'à aujourd'hui, l'a transporté à 8887, rue Arras.Saint-Léonard, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à St-Léonard.ce lie jour de septembre 1973.53948-o Le président.Claude Delisle.Fairfay Corporation Notice is hereby given that \"Fairfay Corporation\" incorporated under Part I of the Québec Companies Act has moved its head office from 1888 Dunkirk Road in the Town of Mount Royal.Province of Québec, to 165 Kindersley Avenue, in the Town of Mount Royal.Province of Québec, effective October 11th.1973.Dated at Montreal.September 17th.1973.Frank Vernon.53946-o Secretary.Fercour Inc.Notice is given that \"Fercour inc.\".incorporated by letters patent dated the 17th day of July.1972.and having its head office in the City of Sorel.has established its principal office at 151 Prince Street.Upon, from and after the date of this notice, the said office will be considered by the company as ils head office.Given at Sorel.Québec, this 1st day of August, 1972.(Seal) F.Cournoyer.President.53947 724009 Foyers CD.Inc.CD.Fire-Place Inc.Notice is hereby given that \"Foyers CD.inc.\u2014 CD.Fire-Place Inc.\", incorporated under Part 1 of the Companies Act by letters patent dated April 19th.1973, and having its head office at 10.707 London Street, Apt.2, Montreal North, where its office was situated up to-day, has moved it to 8887 Arras Street, Saint-Leonard.Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at St-Léonard, this 11th dav of September 1973.Claude Delisle.53948-0 President. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 October 1973, 105' année, «\u2022 il 5S93 Autobus Émilien Côte inc.Avis est donné par la compagnie « Autobus Émilien Côté inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 15 décembre 1972 et ayant son siège social dans la ville de Matane, qu'elle a établi son siège socjal au No 155 de la rue Bergeron à Matane.À compter de la date du présent avis ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Matane.ce 24 septembre 1973.Le président, 53940-o Émii.ikn Côté.Norstowe Holdings Ltd.Gestion Norstowe ltée Avis est par les présentes donné que la compagnie \"Norstowe Ltd.\u2014 Gestion Norstowe ltée ».constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes datées du 17 juillet 1973.a établi son siège social au 4115.rue Sherbrooke-ouest, Wcstmount, Québec.Montréal, le 17 août 1973.(Sceau) Le secrétaire, 53950 Makk Bercuvitz.Institutional Television Systems Ltd.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Institutional Television Systems Ltd.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la I.oi des compagnies par lettres [«tentes en date du 13 août 1971, a transféré son siège social du 6660, boulevard Décarie, en les ville et district de Montréal, au 4988, Place de la Savane, en les ville et district de Montréal.Montréal, le 10 septembre 1973.Le secrétaire, 53953 Joski'ii Gi'banv.Inter-City T.V.& Air Conditioning Co.Ltd.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Inter-City T.V.& Air Conditioning Co.Ltd.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la I/)i des compagnies par lettres patentes en date du 26 septembre 1962, a transféré son siège social du 6656.boulevard Décarie, en les ville et district de Montréal, au 4988, Place de la Savane, en les ville et district de Montréal.Montréal, le 10 septembre 1973.Le secrétaire, 53954 Joseph Gi.bany.Intcr-City T.V.Services Ltd.Avis est par les présentes donné que la compagnie \u2022 Inter-City T.V.Services Ltd.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 14 juillet 1970, a transféré son siège social du 6660, boulevard Décarie, en les ville et district de Montréal, au 4988, Place de la Savane, en les ville et district de Montreal.Montréal, le 10 septembre 1973.Le secrétaire, 53955 M.Schneider.Autobus Émilien Côté inc.Notice is given that \"Autobus Émilien Côté inc.\", incorporated by letters patent dated December 15th, 1972 and having its head office in the Town of Matane, has established its head office at 155 Bergeron Street, Matane.From the date of this notice, the said office shall be considered by the company as its head office.Given in Matane, September 24, 1973.Émilien Coté, 53940 President.Norstowe Holdings Ltd.Gestion Norstowe ltée Notice is hereby given that \"Norstowe Holdings Ltd.\u2014 Gestion Norstowe ltée\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated July 17.1973, has established its head office at 4115 Sherbrooke Street West, Westmount, Québec.Montréal, August 17, 1973.(Seal) 53950-o Mark Bercuvitz, Secretary.Institutional Television Systems Ltd.Notice is hereby given that \"Institutional Television Systems Ltd.\", incorporated under Part I of the Québec Companies Act by letters patent dated August 13th, 1971, has moved its head office from 6660 Décarie Blvd., in the City and District of Montreal, to 4988 Place de la Savane, in the City and District of Montreal.Montreal, September 10th, 1973.Joseph Gibany, Ô3953-0 Secretary.Inter-City T.V.& Air Conditioning Co.Ltd.Notice is hereby given that \"Inter-City T.V.& Air Conditioning Co.Ltd.\", incorporated under Part I of the Québec Companies Act by letters patent dated September 26th, 1962, has moved its head office from 6656 Décarie Blvd., in the City and District of Montreal, to 4988 Place de la Savane, in the City and District of Montreal.Montreal, September 10th, 1973.Joseph Gubany, 53954-0 Secretary.Inter-City T.V.Services Ltd.Notice is hereby given that \"Inter-City T.V.Services Ltd.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated July 14th, 1970, has moved its head office from 6660 Décarie Blvd., in the City and District of Montreal, to 4988 Place de la Savane, in the City and District of Montreal.Montreal, September 10th, 1973.53955-0 M.Schneider, Secretary. 5MII QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October IS.197.1, Vol.105.No.H Laurier Redding Inc.Avis est donné que la compagnie « Laurier Bedding Inc.».corporation constituée par lettres patentes émises en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, en date du 28 août 1957.et ayant son siège social à Montréal, a établi son principal bureau au numéro 8750.rue Verville, dans la ville de Montréal, province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 27 novembre 1972.Le ¦président.53949-0 Lvciek St-Pikrkk.Laurier Bedding Inc.Notice is hereby given that \"Laurier Bedding Inc.\", incorporated by letters patent issued under the provisions of Part I of the Companies Act, dated August 28, 1957 and having its head office in Montreal, did establish its head office at 8750, Verville St., in the City of Montreal, province of Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as l>eing its head office.Montreal, this November 27, 1972.Lucien St-Pierre.53949-u President.M.I.D.Hotels Ltd.Hotels M.I.D.Ltée Avis est donné que la compagnie « M.I.D.Hotels Ltd.\u2014 Hotels M.I.D.Ltée».constituée par lettres patentes datées du 9 mars 1973 et ayant son siège social dans le territoire de la communauté urbaine de Montréal.Québec, a établi son bureau principal à Suite 750.1 Place Ville Marie, Montréal 113.A compter de la «laie du présent avis, ledit bureau est considère par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal.P.Q.en date du 12 mars 1973.Le président, 53951-o F.A.ChBfTECHI.M.I.D.Hotels Ltd.Hotels M.I.D.Ltée Notice is hereby given that \"M.I.D.Hotels Ltd.\u2014 Hotels M.I.D.Ltée\", incorporated by letters patent dated March 9.1973 and having its head office in the Territory of the Montreal Urban Community, Quéliec.has established its head office at Suite 750, 1 Place Ville Marie.Montreal 113.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal.P.Q.as of March 12.1973.F.A.Cheftbchi, 53951 President.1-cs Manufacturiers de Chiffon Maxco inc.Ma\\co Chiffon Mfg.Inc.La compagnie « Leu Manufacturiers de Chiffon Maxco inc.\u2014 Maxco Chiffon Mfg.Inc.» donne avis quelle a changé son siège social du numéro .\"iSKi.rue Charlcroi.Montréal-Nord, au numéro 940.île-du-Moulin.Terrebonne.Le secrétaire.Bernard Caron.53957-o 716391 Lea Manufacturiers de Chiffon Maxco inc.Maxco Chiffon Mfg.Inc.Notice is given that \"Les Manufacturiers de Chiffon Maxco inc.\u2014 Maxco Chiffon Mfg.Inc.\" has transferred its head office from 5816 Charleroi Street.Montreal North, to940 llc-du-Moulin.Terrebonne.Bernard Caron, Secretary.53957 716391 La Société d'lnvcstissrnient Unisig Inc.Avis est donné que la compagnie « La Société d'Investissement l;nisig Inc.» a été constituée en corporation en vertu de la première partie de la lx>i des compagnies (Québec) par lettres patentes en date du vingt août mil neuf cent soixante-treize et, ayant son siège social dans la ville de Montréal, a établi son bureau principal au numéro 9397, de la rue Lajeuncsse à Montréal.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par In compagnie comme son siège social.Montréal, ce 20 septembre 1973.Le secrétaire, 68959-0 V.Pierre Bélanger.La Société d'Investissement l nisig Inc.Notice is hereby given that \"La Société d'Investissement Unisig Inc.\" incorporated under Part I of the Companies Act (Quebec) by letters patent, on 20th of August, 1973 and having its head office in the City of Montreal, Quebec, has established its office at number 9397 de Lajeunessc Street in Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Montreal, this 20th of September, 1973.P.PlEHRE BÉLANGER, 53959-0 Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° il 5895 Sauna Aquarius inc.Avis est par les présentes donné que « Sauna Aquarius inc.*', une compagnie incorporée sous la Loi des compagnies (Québec) par lettres patentes du 5 juin 1970, a établi son siège social à 1183, rue Crescent.Montréal, province de Québec.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Montréal, le 12 janvier 1973.Le secrétaire.53958-0 André Laflammk.Sauna Aquarius inc.Notice is hereby given that \"Sauna Aquarius inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated June 5th, 1970 has established its head office at 1183 Crescent Street, in the City of Montreal, Province of Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Montreal, this 12th day of January.1973.André Laflamme, 53958-0 .Secretary.Société de Recherche en Orientation Humaine Inc.Avis est, par les présentes, donné que « Société de Recherche en Orientation Humaine Inc.».constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi îles compagnies, et ayant son siège social à Montréal, a établi son principal bureau au numéro 2120 est.rue Sherbrooke, district de Montréal.Province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré par la corporation comme étant son siège social.l)onné à longueuil.ce 4c jour de septembre 1973.Le président.53960-\" Moscek Giitimni.Société de Recherche en Orientation Humaine Inc Notice is hereby given that \"Société de Recherche en Orientation Humaine Inc.\", incorporated by letters patent issued under the provisions of Part Three of the Companies Act, and having its head office in Montreal, did established its head office at 2120 Sherbrooke east, district of Montreal.Province of Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.(riven at Longueuil.this 4th day of September, 1973.MON'CKF (iUlTOL'Nl, 33960-n President.Taller.Tucker (Quebec) Ltd.Avis est donné que la compagnie « Tafler.Tucker (Québec) Ltd.« constituée en corporation par lettre-patentes en date du 24c jour de février 1971, et ayant son siège social dans la ville de Montréal où clic avait son bureau situé à 1, carré YVestmount, Chambre 386.l'a transporte à 2050.rue Mansfield.Montréal, H3A I Y?.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie connue étant son siège social.Daté le 12e jour de septembre 1973.Le président.53961-0 Arthur Diamond.Taller.Tucker (Québec) Lid.Notice is hereby given that \"Tafler, Tucker (Québec) Ltd.\" incorporated by letters patent, on the 24th day of February, 1971.and having its head office in the City of Montreal, where its office was situated at One Wcstmoiint Square.Suite 386.has moved it to 2050 Mansfield Street.Montreal.H3A 1 Y9.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated the 12th day of September.1973.Arthur Diamond, 53961 -o President.Impregilo & Spino Itcc Avis est ilonné que la compagnie « Impregilo & Spino ltée », constituée par lettres (latentes datées du 19 septembre 1973 et ayant son siège social à 1205 ouest, rue Louvin a établi son bureau principal à 1205 ouest.ruc_I.ouvin.Montréal.Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, P.Q., c( 13e jour d'octobre 1973.Le président.53995-0 F.A.Cheftechi.Impregilo & Spino Ltd.Notice is hereby given that \"Impregilo & Spino Ltd.\" incorporated by letters patent dated September 19, 1973 and having its head office in 1205 Ixmwin Street West, has established its head office at 1205 \u2014Louvin Street West, Montreal.Quebec.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the Company as being its head office.(liven at Montreal, P.Q.this 13th day of October 1973.M.A.ClIEFTECHI.53995-0 President. 5896 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973, Vol.105, No.11_ Coopérative d'éleveurs d'animaux à fourrure Chinchilla (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement spécial de l'association coopérative < Coopérative d'éleveurs d'animaux à fourrure Chinchilla \", adopté le 16 septembre 1973, changeant son siège social de Mas-son, dans le district électoral de Papineau.à 8271, rue St-Denis, Montréal, dans le district électoral de Laurier.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 54005-o Albert .Iessop.Magasin co-op de Gaspé (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation de l'association coopérative « Magasin co-op de Gaspé ».Le siège social de cette association coopérative est situé à Gaspé, Québec, dans le district électoral «le (iaspé.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives {par intérim), 54006-o Albert .Iessop.Coopérative d'éleveurs d'animaux à fourrure Chinchilla (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the special bylaw of the cooperative association \"Coopérative d'éleveurs d'animaux à fourrure Chinchilla\", adopted on Septeml>er 16, 1973, changing its head office from Masson, in the electoral district of Papineau, to 8271 St.Denis Street, Montreal, in the clectraol district of Laurier.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 54005 Companies and Cooperatives.Magasin co-op de Gaspé (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of the cooperative association \"Magasin co-op de (iaspé\".The head office of this cooperative association is located at Gaspé, Québec, in the electoral district of Gaspé.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 54006 Companies and Cooperatives.Avis divers Club Moto-.Neige Laurenlien Inc.Le ministre des institutions financières, compangics et coopératives donne avis qu'en vertu de I» troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de juillet 1973, constituant en corporation sans capital-actions, sous le nom de « Club Motos-Neige Larentien Inc.», les membres de « Club d'Autos-Neige Laurcntien Inc.», déjà constituée en corporation le ou vers le 28 décembre 1966, en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus, 1964, chapitre 298).Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $100.000.Le siège social de la nouvelle corporation est à Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.53909-o 731072 Miscellaneous Notices Club .Motos-Neige Laurcntien Inc.The Minister of Financial Institutions, Companies and Coo|>eratives gives notice that, under Part III of the Companies Act, he has granted letters patent, dated July 10, 1973, constituting as a corporation without share capital, under the name of \"Club Motos-Neigc Laurentien inc.\", the present members of \"Club d'Autos-Neige Laurentien inc.\", previously incorporated on or about December 28, 1966, under the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 298).The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $100,000.The head office of the new corporation is in St.Jérô me.Judicial District of Terrebonne.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.53909 731072 Associations coopératives Cooperative Associations GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° il 5897 Succession Romain Côté Avis est donné par les présentes que Monsieur Ger-vais Côté, Monsieur Jacques-Omer Côté, Mademoiselle Julienne Côté, Mademoiselle Odyle Côté et Monsieur Louis-Biaise Côté ont accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de Monsieur Romain Côté, en son vivant résidant au 84 De Courval, Victoriaville, le tout suivant acte d'acceptation reçu devant Me Raymond-Pierre Gingras, notaire à Warwick, (19, rue St-Joseph), le 28 septembre 1973 et dont copie a été enregistrée au bureau de la division d'enregistrement d'Arthabaska, à Arthabaska, le 3 octobre 1973 sous le numéro 179,000.Le procureur, 54003-o Raymond-Piehhe GinOras, notaire.Succession Rolland Morissetlc Avis est donné que Dame Odile Brûlé, ménagère, veuve de M.Joseph Morissette, tutrice à son enfant mineure Diane Morissette, Dame Yvonne Morissette, ménagère, épouse de M.Cyprien Hébert, Monsieur Henri Morisette, chauffeur de taxi.Monsieur Léo Morisette, camionneur.Monsieur Pierre Morissette, camionneur, Monsieur Antonio Morissette, rentier.Dame Thérèse Morissette, ménagère, épouse de Roméo Allard, Dame Lucille Morissette, ménagère, épouse séparée de Maurice Lussier, Dame Jeanne-D'Arc Morissette.ménagère, épouse de Berchamans Blanche! te.Dame Rose Ange Morissette, ménagère, épouse de Gaston Laurion.Monsieur Rosaire Morissette.couvreur.Monsicru Jean-Claude Mailhot, mécanicien, Monsieur Marcel Mailhot, étudiant, Dame Denise Mailhot, ménagère, épouse de Jean-Napoléon Degready, Dame Laurette Mailhot, ménagère, épouse de Claude Lemay, Monsieur Alfred Mailhot, employé d'usine.Mademoiselle Diane Mailhot.étudiante.Monsieur René Morissette, camionneur, et Monsieur Gaston Morissette, militaire, ont accepté sous bénéfice d'inventaire par acte signé devant Me André Jean, notaire à Drummondville.215 rue Lindsay, le 24 septembre 1973.enregistré dans Drummond le 27 septembre 1973 sous le numéro 203635, la succession de feu Rolland Morissette, en son vivant camionneur, demeurant à Chemin Hemmings, Drummondville.Drummondville, le 5octobre 1973.Le notaire, 54004-o André Jeas.Succession Fernand Couture Avis est donné que Nicole Cyr, épouse de feu Monsieur Fernand Couture, maîtresse de maison, domiciliée à Granby, au numéro 70 Boulevard Fortin.#3, province de Québec, a accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de feu Monsieur Fernand Couture, son époux décédé le 14 octobre 1972, en vertu d'un acte d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, reçu devant Me Paul-Henri Lacroix, notaire, le 11 avril 1973 et enregistré au bureau d'enregistrement de Lévis, le 13 avril 1973, sous le numéro 173,626.Le notaire.53996-0 Paul-Henri Lacroix.Estate of Romain Côté Notice is hereby given that Mr.Gervais Côté, Mr.Jacques-Omer Côté, Miss Julienne Côté, Miss Odyle Côté and Mr.Louis-Biaise Côté have accepted under benefit of inventory the estate of Mr.Romain Côté, residing in his lifetime at 84 De Courval, Victoriaville, the whole under a deed of acceptance executed before Me Raymond-Pierre Gingras, notary in Warwick, (19 St.Joseph Street), on September 28, 1973, a copy of which deed was registered at the Arthabaska Registration Division Office, in Arthabaska, on October 3, 1973, under number 179,000.Raymond-Piehhe Gingras, Notary, 54003 Attorney.Estate of Rolland Morissette Notice is given that Mrs.Odile Brûlé, housewife, widow of Mr.Joseph Morissette, tutor to her minor child, Diane Morissette, Mrs.Yvonne Morissette, housewife, wife of Mr.Cyprien Hébert, Mr.Henri Morissette, taxi driver, Mr.Léo Morissette, trucker, Mr.Pierre Morissette, trucker, Mr.Antonio Morissette, annuitant, Mrs.Thérèse Morissette, housewife, wife of Roméo Allard, M rs.Lucille Morissette, housewife, wife separate of Maurice l.ussier, Mrs.Jeanne-D'Arc Morissette, housewife, wife of Berchmans Blanchette, Mrs.Rose Ange Morissette, housewife, wife of Gaston Laurion, Mr.Rosaire Morissette, roofer, Mr.Jean-Claude Mailhot, mechanic, Mr.Marcel Mailhot, student, Mrs.Denise Mailhot, housewife, wife of Jean-Napoléon Degready, Mrs.Laurette Mailhot, housewife, wife of Claude Lemay, Mr.Alfred Mailhot, factory worker.Miss Diane Mailhot, student, Mr.René Morissette, trucker, and Mr.Gaston Morissette, member of the Armed Forces, have accepted under benefit of inventory pursuant to a deed signed before Me André Jean, notary in Drummondville, 215 Lindsay Street, on September 24, 1973, registered in Drummond on September 27, 1973, under number 203635, the estate of the late Rolland Morissette, in his lifetime trucker, residing on Hemmings Road, in Drummondville.Drummondville, October 5, 1973.Andre Jean.54004 Notary.Estate of Fernand Couture Notice is given that Nicole Cyr, housewife, widow of Fernand Couture, domiciled in Granby, 70 Fortin Boulevard.Apt.3, (Québec), accepted, according to a deed of acceptance under benefit of inventory executed before Me Paul-Henri Lacroix, notary, on April 11, 1973 and registered at the Levis Registry Office on April 13, 1973 under number 173.626, the estate of her late husband.Fernand Couture, who died on October 14, 1972.Paul-Henri Lacroix, 53996 Notary. 5S9S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 1973.Vol.105, No.jl Massawippi Valley Snowmobile Club Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour d'avril 1973, constituant en corporation sans capital-actions, les membres de « Massawippi Valley Snowmobile Club Inc.», constituée en corporation le ou vers le 14e jour de septembre 1970, en vertu de la Loi des clubs de récréation.Statuts refondus, 1964, chapitre 298.Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $40,000.Le siège social de la nouvelle corporation est à Ascot, district judiciaire de Saint-François.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.53909 731785 Massawippi Valley Snowmobile Club Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, bearing date the 18th day of April, 1973, to constitute as a corporation without share capital, the members of \"Massawippi Valley Snowmobile Club Inc.\", incorporated under the Amusement Clubs Act, Revised Statutes.1964.Chapter 298, on or about the 14th day of September 1970.The amount of which the annual revenue which the corporation may hold lie limited to $40,000.The head office of the new corporation is at Ascot, judicial District of Saint-François.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.53909-o 731785 The Evangelical Free Church of America in the Province of Québec Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis par les présentes qu'il a accordé des lettres patentes en date du 31e jour d'août 1973, constituant en corporation régie par la Loi des corporations religieuses, chapitre 75 des Statuts de 1971, les membres de « The Evangelical Free Church of America in the Province of Québec», constituée en corporation en vertu des Lois 10-11 Elizabeth II (1962), Statuts du Quebec, chapitre 107.le 14e jour do mars 1962.Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de 81,000,000.Le siège social de la nouvelle corporation est à Magog, district judiciaire de Saint-François.Le directeur du service des compagnies, Pierre Dksjahdins.53909 732555 The Evangelical Free Church of America in the Province of Québec Notice is hereby given that, letters patent bearing dated the 31st day of August, 1973, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to constitute as a corporation governed by the Religious Coiporations Act, Chapter 75, 1971, the members of \"The Evangelical Free Church of America in the Province of Québec\", incorporated under 10-11 Elizabeth II (1962) S.Q.Chapter 107.on the 14th day of March, 1962.The amount to which the value of the immoveable property which the corporation mav own or hold is to be limited is $1,000,000.The head office of the new corporation is at Magog, judicial District of Saint-François.Pierre Desjahdins, Director of the Companies Service.53909-o 732555 Société Hypothécaire UNE BNS Mortgage Corporation Avis est par les présentes donné qu'un pemis a été émis par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, le 28 juin 1973.à la « Société Hypothécaire BNE \u2014 BNS Mortgage Corporation », l'autorisant à faire affaires dans la province de Québec en vertu de la Loi des sociétés de prêts et de placements.Daté à Montréal, Québec, ce 10e jour de septembre 1973.53612-38-4-0 L'agent principal, R.D.Weldon.BNS Mortgage Corporation Société Hypothécaire BNE Notice is hereby given that, on June 28.1973.a license was granted by the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives to \"BNS Mortgage Corporation \u2014 Société Hypothécaire BNE.\" authorizing it to carry on business in the Province of Québec pursuant to the provisions of the Loan and Investment Societies Act.Dated at Montreal.Québec, this 10th day of Sep-tcmlier, 1973.R.D.Weldon, 53612-38-4-o Chief Agent. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n' 41_5899 Teledyne Canada liai l'ai Limited Avis est donné que le 22e jour d'août 1973.le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a accordé un permis à la compagnie « Hard-facing Alloys Limited », l'autorisant à exercer son commerce dans la province sous le nouveau nom de « Teledyne Canada Harfac Limited », en vertu des dispositions de la Loi des compagnies étrangères, Statuts refondus, 1964, chapitre 282.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur Claude Girard, 500.suite 609, Grande-Allée Est, Québec.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives.Fernand Lalonde.53909 PA: 95-71 Teledyne Canada Harfac Limited Notice is given that, on 22nd day of August, 1973, a new license was granted by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to \"Hard-facing Alloys Limited\", authorizing it to carry on business in the Province under its new name of \"Teledyne Canada Harfac Limited\", pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes, 1964, chapter 282.The chief agent for the purpose of receiving services in proceeding against the said company, is Mr.Claude Girard, Suite 609.500 Grande-Allée East, Québec.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.53909-o PA: 95-71 Household Rcaity Corporation Limited Avis est donné que le 10e jour de septembre 1973, le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a accordé un permis à la compagnie « Household Realty Coporation Limited », l'autorisant à exercer son commerce dans la province en vertu des dispositions de la Loi des sociétés de prêts et de placements, Statuts refondus.1964, chapitre 289._ L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur Marc-Pierre Forget, 2990, rue Soissons.Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 1.Carré Westmount.Westmount.district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives.Fernand Lalonde.53909 SPP: 2-73 Household Realty Corporation Limited Notice is given that, on 10th day of September, 1973, a license was granted by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to \"Household Rcaity Corporation Limited\", authorizing it to carry on business in the Province pursuant to the provisions of the Loan and Investment Societies Act, Revised Statutes, 1964, chapter 289.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Marc-Pierre Forget, 2990 Soissons Street.Montreal.The principal office of the company in the Province is at 1 Westmount Square, Westmount judicial District of Montreal.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.53909-o SPP: 2-73 Monarch Industries (1973) Limited Avis est donné que le 24e jour de septembre 1973, le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a accordé un permis à la compagnies « Monarch Machinery Limited » l'autorisant à exercer son commerce dans la province sous le nouveau nom de « Monarch Industries (1973) Limited », en vertu des dispositions de la Loi des compagnies étrangères, Statuts refondus, 1964, chapitre 282.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives, Fernand Lalonde.53909 PA: 29-65 Monarch Industries (1973) Limited Notice is given that on 24th day of September.1973, a new license was granted by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to \"Monarch Machinery Limited\", authorized it to carry on business in the Province under its new name of \"Monarch Industries (1973) Limited\", pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes, 1964, chapter 282.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.53909-o PA: 29-65 Compagnies étrangères Extra-Provincial Companies Permis Licenses 5900 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13.1973, Vol.105, No.11 International American Real Estate Syndications Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « International American Real Estate Syndications Ltd.» a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est mon-sieur.lolin Aster.1227.rue Sherbrooke ouest.Montréal.l,e bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 1227.nie Sherbrooke ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le .mus-ministre des institutions financières.compagnies et coopê rati ces.Fernand Lalonde.53909 PA: 53-73 International American Real Estate Syndications Ltd.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"International American Real Estate Syndications Ltd.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company Mr.John Aster, 1227 Sherbrooke Street West, Montreal.The principal office of the company in the Province is at 1227 Sherbrooke Street West.Montreal, judicial District of Montreal.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58909-0 PA: 53-73 Golden Briar Mines Limited Avis est donné que la compagnie « Golden Briar Mines Limited .a été autorisée à vendre, ou autrement aliéner dans la province de Québec, ses actions, stocks, certificats d'actions, obligations et autres valeurs.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur Michel Blouin, 612, rue St-Jacques, suite 703.Montrée], Le bureau principal de ladite compagnie dans la province est établi à 612.rue St-Jacques, suite 703, Montréal, district judiciaire île Montréal.I* sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Pgknand Lalonde.53909 PVA: 2-73 Golden Briar .Mines Limited Notice is given that \"(iolden Briar Mines Limited\", has been authorized to sell, or otherwise alienate in the Province of Québec, its shares, stocks, stock-certificates, debentures and other securities.The chief agent for the purpose of receiving services in proceeding against the said company, is Mr.Michel Blouin.612 St.James Street.Suite 703.Montreal.The principal office of the said company in the Province is at 612 St.James Street.Suite 730.Montreal, judicial District of Montreal.Fernand Lalondk, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.53909-n PVA: 2-73 Citrust Developments Limited Avis est donné qu'en vertu île la Loi des compagnies étrangères, la compagnie \u2022 Citrust Developments Limited \u2022 a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins île recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur William Ix-vitt.de Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 1010.rue Sainte-Catherine ouest, suite 600, Montréal, district judiciaire de Montréal./.«¦ sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives.Fkkxani» Lalonde.\u2022\"\u2022'«'\u2022'\"\" PA: 73-73 Citrust Developments Limited Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act.\"Citrust Developments Limited\", has lieen authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.William Levitt, of Montreal.The principal office of the company in the Province is at 1010 St.Catherine Street.West, Suite 600, Montreal, judicial District of Montreal.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.53909-O PA: 73-73 \\rlc\\ I lnl.li- Products, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Artex Hobby Products, Inc.» a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur Raymond Eric Parsons, de Montréal.Artex Hobby Products.Inc.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"Artex Hobby Products, Inc.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Raymond Eric Parsons, of Montreal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105- année, n° il 5901 Le bureau principal «le la compagnie dans la province est établi à 630, boulevard Dorchester ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le tous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Fernand Lalonde.53909 PA: 80-73 Canadian Cellulose Company, Limited Avis est donné qu'en vertu «le la Loi des compagnies étrangères, la compagnie 8 Canadian Cellulose Company, Limited » a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur D.T.Dingle, 630, boulevard Dorchester ouest, 22e étage, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 630, boulevard Dorchester ouest, 22e étage, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Fkhnand Lalonde, 53909 PA: 54-73 The principal office of the company in the Province is at 630 Dorchester Boulevard West, Montreal, judicial District of Montreal.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.53909-o PA: 80-73 Canadian Cellulose Company, Limited Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"Canadian Cellulose Company, Limited\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.D.T.Dingle, 630 Dorchester Boulevard West, 22nd Floor, Montreal.The principal office of the company in the Province is at 630 Dorchester Boulevard West, 22nd Floor, Montreal, judicial District of Montreal.Fernand Lalonde.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.53909-o PA: 54-73 Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions La Caisse Populaire de Ste-Catherine de Sienne La Caisse Populaire de Ste-Catherine de Sienne (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 29 mai 1973 par « La Caisse Populaire de Ste-Catherine de Sienne » modifiant son territoire qui était 8 la paroisse Sainte-Catherine-de-Siennc » en celui de la « Ville de Trois-Rivièrcs-Ouest.Ville de Trois-Rivières, Pointe-du-Lac.La Visitât ion-de-la-Pointe-du-Lac ».Québec, le 28 septembre 1973.Le sous-)iiiuistre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim.) 53964-0 Albert J;;ssoi\\ La Caisse Populaire de Saiut-Kpiphanc (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 4 juillet 1973 par « La Caisse Populaire de Saint-Épiphane » modifiant son territoire qui était la « Paroisse de Saint-Êpiphanc » en celui de la « Paroisse de Saint-Épiphane et Saint-François-Xavier-dc-Viger ».Québec, le 28 septembre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim).53966-0 Albert Jessoi\\ (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, has approved the bylaw adopted on May 29.1973.by \"La Caisse Populaire de Stc-Catherine-de-Sienne\" changing its territory which was \"the Parish of Ste.Catherine-de-Sienne\" to that of \"Town of Trois-Rivières-West.City of Trois-Rivières.Pointe-du-Lac.La Visitation-de-la-Pointe-du-Lac\".Québec, September 28.1973.Albert .Iessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 53964 Companies and Cooperatives.La Caisse Populaire de Saint-Épiphane (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, has approved the bylaw adopted on July 4.1973.by \"La Caisse Populaire de Saint-Épiphane\" changing its territory which was the \"Parish of St.Épiphane\" to that of \"Parish of St.Épiphane and St.Francois-Xavier-de-Viger\".Québec, September 28, 1973.Albert .Iessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 53966 Companies and Cooperatives, 5902 QUEBEC OFFICIAI.OAZETTE.October 13.1973, Vol.105.No.41 La Caisse Populaire St-Philippe des Trois-Rivières (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 19 juin 1973 par «La Caisse Populaire St-Philippe des Trois-Rivières » modifiant son territoire qui était « établi aux limites de la paroisse St-Philippe à Trois-Rivières » en celui de la « Ville des Trois-Rivières, Cité du Cap-de-la-Madeleine.Ville de Trois-Rivières Ouest ».Quel.ee, le 28 septembre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 53952-0 Albert .Iessop.La Caisse Populaire de Ste-Croix de Shav» inigan (Loi des Caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 13 juin 1973 par « La Caisse Populaire de Ste-Croix de Sliawinigan » modifiant son territoire qui était « la paroisse de Ste-Croix de Sliawinigan » en celui de la « Cité de Sliawinigan, Ville de Shawinigan-Sud.Ville de (irand'Mère.Village Baie-de-Saliwinigan, Paroisse Saint-Gérard-des-Lauretntides.Village Saint-Boniface-de-Shawinigan ».Québec, le 28 septembre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim).53065-o Albert .Iessop.La Caisse Populaire de Mont-Rolland (Loi des Caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 20 juin 1973 par « La Caisse Populaire de St-Joseph du Mont-Rolland » changeant son nom en celui de « l,a Caisse Populaire rte Mont-Rolland ».Québec, le 28 septembre 1973.Le sous-mimslrc des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 53908-o Albert .Iessop.La Caisse Populaire de Richmond (Loi des Caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 26 juin 1973 par « La Caisse Populaire de Richmond » modifiant son territoire qui était la « Paroisse Stc-Famille » en celui de la « Ville de Richmond, Canton de Cleveland.Village de Melbourne, Canton de Melbourne et Village de Kingsbury Québec, le 28 septembre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim).53969 0 Albert .Iessop.La Caisse Populaire St-Philippe des Trois-Rivières (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, has approved the by-law adopted on June 19.1973, by \"La Caisse Populaire St-Philippe-des-Trois-Rivières\" changing its territory which was \"within the limits of the Parish of St.Philippe in Trois-Rivières\" to that of \"City of Trois-Rivières.City of Cap-dc-la-Madcleine, Town of Trois-Rivières-West\".Québec.September 28.1973.Albert .Iessop.Acting Deputy Minister of Financial Institions.53952 Companies and Cooperatives.La Caisse Populaire de Ste-Croix de Sliawinigan (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, has approved the bylaw adopted on June 13.1973, by \"La Caisse Populaire de Ste-Croix-dc-Shawinigan\" changing its territory which was \"the Parish of Ste.Croix-dc-Shawinigan\" to that of \"City of Sliawinigan.Town of Shawinigan-Soutli.City of (irand'Mère, Village of Baic-dc-Shawinigan, Parish of St.Cérard-des-Lau-rentides.Village of St.Boniface-dc-Shawinigan\".Québec.Septemlier 28, 1973.Albert .Iessop.Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 53965 Companies and Cooperatives.La Caisse Populaire de M on i - Holland (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, has approved the bylaw adonted on June 20, 1973, by \"I,a Caisse Populaire de St-Joseph-du-Mont-Rolland\" changing its name to that of \"La Caisse Populaire de Mont-Rolland\".Québec.September 28, 1973.Albert .Iessop, Acting Deputy Minister of Financial 53968 Institutions.Companies and Cooperatives.La Caisse Populaire de Richmond (Savings and Credit Union Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, has approved the bylaw adopted on June 26, 1973, by \"La Caisse Populaire de Richmond\" changing its territory which was the \"Parish of Ste.Famille\" to that of Town of Richmond.Township of Cleveland, Village of Melbourne, Township of Melbourne and Village of Kingsbury\".Québec.September 28, 1973.Albert .Iessop, Acting Deputy Minister of Financial 53969 Institutions, Companies and Cooperatives. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° il 5903 La Caisse Populaire de Cadillar (Loi de' Caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation de la caisse d'épargne et de crédit « La Caisse Populaire de Cadillac ».Le territoire dans lequel la caisse recrutera ses membres sera: « la ville de Cadillac ».Le siège social de cette caisse «l'épargne et de crédit est situé à Cadillac, dans le district électoral «le Rouyn-Noranda.Cette caisse sera affiliée à l'Union Régionale «les Caisses Populaires Desjardins de l'Ouest-Québécois.Québec, le 28 septembre 1973.1* sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 53967-0 Albert .Iessop.La Caisse Populaire de Cadillac (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, has approved the formation of the savings and credit union \"La Caisse Populaire de Cadillac\".The territory in which the union shall recruit its members shall be: \"the Town of Cadillac\".The head office of this savings anil credit union is located in Cadillac, in the Electoral District of Rouyn-Noranda.This union shall be affiliated to the Union Régionale des Caisses Populaires Desjanlins de l'Ouest-Qué-bécois.Québec, September 28, 1973.Albert .Iessop, Acting Deputy Minister of Financial 53967 Institutions, Companies and Cooperatives.Changement de nom Demandes Loi du Change of name \u2014 Act Applications Jean Mary LeBlanc Jean Mary LeBlanc.célibataire, domiciliée et résidant au numéro 5579, rue St-Urbain.«lans la ville et le district de Montréal, s'adressera au lieutant-gouverneur en conseil de la province de Québec afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Jean Arsenault.Montréal, ce 24 septembre 1973.L'avocat, 53886-40-2-o Bernard Sepinwai.l.Marie Lucille Jeanninc Larivicrc Marie Lucille Jeanninc Larivière, célibataire, domiciliée et résidant au numéro 55 est.rue Duluth.«lans les ville et district de Montréal, s'ailressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province etition or make representations may apply to the undersigned before October 16, 1973.October 5.1973.Me Denis Savignac, Member of 'he Board and Secretary.2100 Drummond Street.Montreal 107.P.Q.539S0-M Curatelle publique Succession Bruno A.Charlehois Succession dc Bruno A.Charlehois.en son vivant de l'Epiphanie, décédé le 31 janvier 1972.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Lui delà curatelle publique (( 'hapitre 81 des lois du Quebec 1971).il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.I.E Cl'HATEl 11 ri ULIC 1)1 QlÉBEC.9310.boul.St-Laurent.Montréal 354, Que., H2N 1X6.53981-0 Public Curatorship Estate of Bruno A.Charlebois Estate of Bruno A.Charlebois.during his lifetime of l'Epiphanie, who died on January 31.1972.Under the authority of the Public Curatorship Act.(Statutes of Quebec.1971.Chapter 81), the undersigned gives notice that he is curator e.r officio to this estate and that he will receive payment of any debt owing to this estate and will evidence any claim against said estate at the address given lielow.The Public Curator of Québec, 9310 St.lotirent Boulevard.Montreal 354, Québec, H2N 1X6.53981 GA'/.ETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973.105' année, n\" Al 5911 Succession Pauline Houle Succession de Pauline Houle, en son vivant de Outremont, décédec le 27 juillet 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre SI des lois du Québec 1971).il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le CuitATEUU im11uc lit) Ql'éuec.9311).boul.St-Laurent.Montréal 354.Que.H2N\" I N(i.53982-0 Succession Gilberle Proulx (Mlle) Succession de Mlle (iilbcrte Proulx.en son vivant de Montréal, décédéc le 29 août 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre SI des lois du Québec 1971).il est administracur d'olfiec à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers lu succession et la preuve de toute réclamation contre clic.Le CruATKiu ruui.ic ni' Québec.9310.boul.St-Laurent.Montréal 354.Que.H2X 1X0.530S3-o Estate of Pauline Houle Estate of Pauline Houle, during her lifetime of Outremont, who died on July 27, 1973.Under the authority of the Public Curatorship Act, (Statutes of Québec.1971.Chapter81), the undersigned gives notice that he is curator ex officio to this estate and that he will receive payment of any debt owing to this estate and will evidence any claim against said estate at the address given below.TlIE PUBLIC CuitATOH of QUÉBEC, 9310 St.Laurent Boulevard.Montreal 354, Quéliec.H2N' 1XG 53982 Estate of Gilbcrte Proulx (Mile) Estate of Mile (iilbcrte Proulx.during her lifetime of Montreal, who died on August 29.1973.Under the authority of the Public Curatorship Act.(Statutes of Quebec.1971.Chapter 81).the undersigned gives notice that he is curator ex officio to this estate and that he will receive payment of any debt owing to this estate and will evidence any claim against said estate at the address given below.Tm-; Public (Yhatoh of Québec, 9310 St.Laurent Boulevard.Montreal 354.Quebec.H2X I X6.53983 Société d'habitation Québec Housing du Québec Corporation Office municipal d'habitation de Drummondvillc-Stid .Municipal Housing Bureau of Dnmimondvillc-Sud Avis est donné qu'en vertu de l'article 55 de la Loi tic la Société d'habitation du Québec (chapitre 55 des lois de I9(i(i-19(i7).le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes, eu date du vingtième jour d'août 1973.constituant en corporation sans but lucratif: Vvon Cormier, gérant.85.125e Avenue: Edgar René, agent d'assurances.1870.rue Fradet: Marcel Bonin.employé d'usine.Il 10.boulevard Mercure: Roger Deniers, garagiste.820.110e Avenue; Clément Boisvcrt.technicien.1420.rue Goupil; Henri Montininy.contremaître.1227.rue Cha-banel: Paul-Emile Bordclcau.notaire.1555.rue Daniel: Roger Parenteau.avocat.1450.rue Fradet et Gilles Gagnon.avocat.2035.rue Daniel, tous domiciliés à Drummondvi Ile-Sud ; pour les fins suivantes: acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitation à loyer modique pour personnes à faible revenu.Le siège social de la corporation est situé dans les limites du territoire de la ville de Drummonilville-Sud.district judiciaire de Drummond.Société d'habitation du Québec.Le secrétaire.53988-0 Me Jean-Luc Lesace, notaire.Oilier municipal d'habitation de Drummond ville-Sud Municipal Housing Bureau of Drumniondvillc-Sud Notice is given that under Article 55 of the Quebec Housing Corporation Act (I9(i0-19(i7.chapter 55).the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the (irent Seal of the Province, bearing date of the twentieth day of August 1973.incorporating as a nonprofit corporation: Vvon Cormier, manager.85, 125c Avenue: Edgar Bene, insurance agent.1870.Fradet Street; Marcel Bonin.factory-worker.1110.Mercure Boulevard: Roger Deniers, garage mechanic.820.110c Avenue; ('lenient Boisvcrt.technician.1420.Goupil Street: Henri Moutminy.foreman.1227.Chabancl Street: Paul-Emilc Bordclcau.notary.1555.Daniel Street; Roger Parcnteau.lawyer.1450.Fradet Street and Gilles Gagnon.lawyer.2035.Daniel Street, all are living in Drummondvillc-Siid: for the following purpose's: to acquire, to construct and to administer low rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the territory of the municipality of DrummondviUe-Sud.judicial district of Drummond.Quebec Housing Corporation.Me Jean-Luc Lesage, Notary.539SS-0 Secretary. 5912 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 13, 197.3, Foi.105, No.il Office municipal d'habitation de Sherbrooke Municipal Housing Bureau of Sherbrooke Avis est donné qu'en vertu de l'article 55 de la Loi de la Société d'habitation du Québec (chapitre 55 des lois de 1966-1967), le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes supplémentaires en date du 10.septembre 1973 modifiant les règles relatives à l'exercice des pouvoirs et à la désignation des membres et administrateurs de l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke.Société d'habitation du Québec, lœ secrétaire.53989-u Mis Jean-Luc Lesage, notaire.Office municipal d'habitation d'East Angus Municipal Housing Bureau of East Angus Avis est iloiiné qu'en vertu de l'article 55 de la Loi de la Société d'habitation du Quéliec (chapitre 55 des lois de 1966-1967).le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes, en date du vingtième jour d'août 1973.constituant en corporation sans but lucratif: Alphonse (îudbout, contremaître.146, rue Collège; Arthur Bibcau.retraité.102, rue Saint-François; Robert Fournier.machiniste.150.rue Saint-Hilairc; Jean-Paul Lcpitrc.soudeur.154.rue Duplin; Gaston Labbé.bijoutier.192.boulevard Brousseau; Gaston Descoteaux.imprimeur.57.rue West (iate et Gaétan Lagueux.papetier.42.rue Saint-David, tous domiciliés à East Angus; pour les fins suivantes: acquérir, construire cl administrer des immeubles d'habitation à loyer modique pour personnes à faible revenu.Le siège social de la corporation est situé dans les limites du territoire de la ville d'East Angus, district judiciaire de Saint-Francois.Société d'habitation du Québec.Le secrétaire.53990-u Me Jean-Luc Lesage, notaire.Loi électorale du Québec Avi» Je nomination d'agent officiel (article 37») Je donne avis, par les présentes, que M.Claude Longtin, chef du Parti Républicain, a nommé, conformément aux dispositions de l'article 375 de la Loi électorale, la personne suivante pour agir comme agent officiel dudit Parti Républicain au cours des élection dont le scrutin est fixé au 29 octobre 1973: M.Paul Vachon, agent d'affaires, 2205 rue Hcnri-Ifourassa, Montréal, Que.Québec, le 9 octobre 1973.Le président général des élections, ., Juge de la Cour provinciale, 93970-o François Dhouin.Office municipal d'habitation de Sherbrooke Municipal Housing Bureau of Sherbrooke Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1907.Chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued supplementary letters patent under the Great Seal of the Province bearing date of the tenth day of September 1973 modifying the rules for the exercising of the powers and the appointment of the members and directors of Municipal Housing Bureau of Sherbrooke.Quebec Housing Corporation.Mi-; Jean-Luc Lesage, Notary, 33989-0 Secretary.Office municipal d'habitation d'East Angus Municipal Housing Bureau of East Angus Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1960-1967, Chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, bcaringdateof the twentieth day of August 1973.incorporating as a nonprofit corporation: Alphonse Godbout, foreman, 146, Collège Street; Arthur Bibcau, retired, 102, Saint-François Street; Robert Fournier.machinist, 150, Saint-Hilaire Street; Jean-Paul Lcpitre, solder-man, 154, Duplin Street; Gaston Labile, jeweller, 192, Brousseau boulevard; Gaston Descoteaux.printer, 57, West Gate Street and Gaétan Lagucux.paper-maker, 42, Saint-David Street; all are living ill East Angus; for the following purposes: to acquire, to construct and to administer low rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the territory of the municipality of East Angus, judicial district of Saint-François.Québec Housing Corporation.Me Jean-Luc Lesage, Notary, 53990-O Secretary.Québec Election Act Notice of appointment of official agent (section 375) I give notice, by these presents, that Mr.Claude, Longtin, Leader of the Republican Party, has appointed pursuant to the provisions of section 375 of the Election Act, the following person to act as official agent of the said Republican Party during the election for which voting is fixed for October 29, 1973: Mr.Paul Vachon, general agent, 2205 Henri-Bou-rassa Street, Montreal, Que.Québec, October 9, 1973.François Drouin, Judge of the Provincial Court, 53970-o Chief Returning-Officer. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° il 5913 Avis concernant une agence de publicité (article 377) Je donne avis, par les présentes, que l'agence de publicité « Conceptat Inc.», 1500 rue Stanley, suite 408, Montréal, est reconnue comme mandataire de monsieur Roger Ranger, agent officiel de monsieur François Desrosiers, candidat du Parti Québécois dans le district électoral de L'Acadie pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 octobre 1973.Québec, le 2 octobre 1973.Le président général des élections, Francois Drouin, 53970-o Juge de la Cour provinciale.Avis concernant une agence de publicité (article 377) Je donne avis, par les présentes, que l'agence de publicité « Conceptat Inc.», 1500 rue Stanley, suite 408, Montréal, est reconnue comme mandataire de monsieur André Levasseur, agent officiel de monsieur Gaston Laurion, candidat du Parti Québécois dans le district électoral de Westmount pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 octobre 1973.Québec, le 2 octobre 1973.Le président général des élections, François Drouin, 53970-o Juge de la Cour provinciale.Notice concerning a publicity agency (section 377) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Conceptat Inc.\", 1500 Stanley Street, Room 408, Montreal, is recognized as the authorized agent of Mr.Roger Ranger, official agent of Mr.François Desrosiers, Parti Québécois candidate in the electoral district of L'Acadic for the present election, for which voting is fixed for October 29, 1973.Québec, October 2nd, 1973.François Drouin, Chief Returning-Officer, 53970-o Judge of the Provincial Court.Notice concerning a publicity agency (section 377) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Conceptat Inc.\", 1500 Stanley Street, Room 408, Montreal, is recognized as the authorized agent of Mr.André Levasseur, official agent of Mr.Gaston Laurion, Parti Québécois candidate in the electoral district of Westmount for the present election, for which voting is fixed for October 29, 1973.Québec, October 2nd, 1973.François Drouin, Chief Returning-Officer, 53970-o Judge of the Provincial Court.Avis concernant une agence de publicité (article 377) Je donne avis, par les présentes, que l'agence de publicité « Conceptat Inc.», 1500 rue Stanley, suite 408, Montréal, est reconnue comme mandataire de monsieur Louis Lefebvrc, agent officiel de M.Serge Brodeur, candidat du Parti Québécois dans le district électoral de Robert Baldwin pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 octobre 1973.Québec, le 2 octobre 1973.Le président général des élections.François Drouin, 53970-o Juge de la Cour provinciale.Notice concerning a publicity agency (section 377) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Conceptat Inc.\".1500 Stanley Street, Room 408, Montreal, is recognized as the authorized agent of Mr.Louis Lefebvre, official agent of Mr.Serge Brodeur, Parti Québécois candidate in the electoral district of Robert Baldwin for the present election, for which voting is fixed for October 29.1973.Québec.October 2nd, 1973.François Drouin, Chief Returning-Officer, 53970-o Judge of the Provincial Court.Avis ccnccrnant une agence de publicité (article 377) Je ilonne avis, par les présentes, que l'agence de publicité « Les Productions Proms Limitée », 48, rue Principale, Hull, est reenonue comme mandataire de monsieur Guy Lesage, agent officiel de monsieur Oswald Parent, candidat du Parti Libéral du Québec dans le district électoral de Hull pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 octobre 1973.Québec, le 2 octobre 1973.Le président général des élections.François Drouin.53970-o Juge de la Cour provinciale.Notice concerning a publicity agency (section 377) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Les Productions Proms Limitée\".48 Principale Street, Hull, is recognized agent of Mr.Guy Lesage, official agent of Mr.Oswald Parent, Québec Liberal Party candidate in the electoral district of Hull for the present election, for which voting is fixed for October 29, 1973.Québec, October 2nd, 1973.François Drouin, Chief Returning-Officer, 53970-o Judge of the Provincial Court.Avis concernant une agence de publictiè (article 377) Je donne avis, par les présentes, que l'agence de publicité « Conceptat Inc.», 1500 iuc Stanley, suite 408.Montréal, est reconnue comme mandataire de M.Jean-Luc Gagnon, agent officiel de M.Georges-Etienne Notice concerning a publicity agency (section 377) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Conceptat Inc.\", 1500 Stanley Street.Room 408, Montreal, is recognized as the authorized agent of Mr.Jean-Luc Gagnon, official agent of Mr.Georges- 5914 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.October 13.1973.Vol.105.No.il Cartier, candidat du Parti Québécois dans le district électoral de Notre-Dame-de-C.râce pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 octobre 1973.Québec, le 9 octobre 1973.Le président général des élections.François Drouin.53970-o .luge de la Cour provinciale.tris concernant une agence de publicité (article 377) Je donne avis, par les présentes, que l'agence de publicité « Conceptat Inc.», 1500 rue Stanley, suite 40S, Montréal, est reconnue comme mandataire de M.Pierre St-Onge.agent officiel de M.Roland Dussault.candidat du Parti Québécois dans le district électoral de Châteauguay pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 octobre 1973.Québec, le S octobre 1973./.*¦ président général des élections.François Drouin, 53970-o .luge de la Cour provinciale.Etienne Cartier, Parti Québécois candidate in the electoral district of Notre-Damc-dc-Crâce for tlie present election, for which voting is fixed for October 29.1973.Québec, October 9, 1973.François Drouin.Chief Returning-Officer, 53970-o Judge of the Provincial Court.Notice concerning a publicity agency (section 877) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Conceptat Inc.\".1500 Stanley Street, Room 408.Montreal, is recognized as the authorized agent of Mr.Pierre St-Ongc.official agent of Mr.Roland Dussault.Parti Québécois candidate in the electoral district of Châteauguay for the present election, for which voting is fixed for October 29.1973.Québec, October 8.1973.François Dhoi in.Chief Returning-Officer.53970-o Judge of the Provincial Court.Avis concernant une agence de publicité (article 377) Je donne avis, par les présentes, que l'agence de publicité» Conceptat Inc.», 1500 rue Stanley, suite 408, Montréal, est reconnue comme mandataire de M.Benoit Patar.agent officiel de M.Jean-Paul Ross, candidat du Parti Québécois dans le district électoral de Verdun pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 octobre 1973.Québec, le 8 octobre 1973.Le président général des élections.François Drouin, 53970-o ,lugt de la Cour provinciale.Notice concerning a publicity agency (section 377) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Conceptat Inc.\".1500 Stanley Street.Room 408, Montreal, is recognized as the authorized agent of Mr.Benoît Patar.official agent of Mr.Jean-Paul Ross, Paiti Québécois candidate in the electoral district of Verdun for the present election, for which voting is fixed for Octobei 29.1973.Québec, October 8, 1973.François Drouin.Chief Returning-Officer.53970-o Judge of llic Provincial Court.Avis concernant une agence de publicité (article 377) Je donne avis, par les présentes, «pie l'agence de publicité « Conceptat Inc.», 1500 rue Stanley, suite 408.Montréal, est reconnue comme mandataire de M.Paul-Guy Martin, agent officiel de M.Jean-François Keablc.candidat du Parti Québécois dans le district électoral de Saint-Laurent pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 octobre 1973.Québec, le 8 octobre 1973.Le président général des élections.François Drouin, o3970-o ./ugc de la Cour provinciale.Notice concerning a publicity agency (section 377) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Conceptat Inc.\", 1500 Stanley Street.Room 408.Montreal, is rocognized as the authorized agent of Mr.Paul-Guy Martin, official agent of Mr.Jean-François Kcable.Parti Québécois candidate in the electoral district of Saint-Laurent for I he present election, for which voting is fixed for October 29, 1973.Quebec.October 8.1973.Francois Drouin.C'A ief Ret urn ing-Officer, 53970-o Judge of the Provincial Court.Ads concernant une agence de publicité (article 377) Je donne avis, par les présentes, que l'agence de pu-îcite « Conceptat Inc.», 1500 rue Stanley, suite 408.Lontreal, est reconnue comme mandataire de M.Notice concerning a publicity agency (section 377) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Conceptat Inc.\", 1500 Stanley Street.Room 408, Montreal, is recognized as the authorized agent GAZETTE OFFICIELLE DC QUEBEC.13 octobre 1978, tor,- année, n* 11 5915 Charles-A.Ixfelivrc, agent officiel «le M.Anilré Nor-inanrleau, candidat du l'arti Québécois dans le district électoral «le Mont-Royal pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 octobre 1973.Québec, le 8 octobre 1973.Le président général des élections, François DliOL'in, 53970-o -luge de la Cour provinciale.Aris concernant une agence de publicité (article .177) Je ilontle uvis, par les présentes, que l'agence île publicité \u2022 Conceptat Inc.», 1500 nie Stanley, suite 40S.Montréal est reconnue comme mandataire de M.(iilles Rliéaiilt.agent officiel de M.(iilles Coté, candidat du l'arti Quéliécois dans le district électoral de Jacques-Cartier pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 octobre 1973.Québec, le S octobre 1973.I.c président général des élections.François Diioi in, 53970-o Juge de la Cour provinciale.Avis concernant une agence de publicité {article 377) Je donne avis, par les présentes, que l'agence de publicité.« Conceptat Inc.1500 rue Stanley, suite 40S.Montréal, est reconnue comme mandataire de M.Claude-M.Gencst, agent officiel de M.Jean-Guy Mutphy, candidat du l'arti Quéliécois dans le district électoral de Laprairie pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 octobre 1973.Québec, le S octobre 1973./.c président général des élections, François Duoi in, 53970-o Juge de la Cour provinciale.Président d'élection Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 de la Loi électorale du Québec, j'ai fait, pour remplir la charge de président d'élection, la nomination suivante: of Mr.Charles-A.Lefebvrc.officiai agent of Mr.André Normandcau.Parti Québécois candidate in the electoral district of Mount-Royal for the present election, for which voting is fixed for October 29, 1973.Quebec, October 8, 1973.François Drouin, Chief Returning-Officer, 53II70-o Judge of the Provincial Court.Notice concerning a publicity agency (section 377) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Conceptat Inc.\".1500 Stanley Street.Room 40S, Montreal, is recognized as the authorized agent of Mr.Oilles Rhcault.official agent of Mr.(iilles Côté.Parti Québécois candidate in the electoral district of Jacques-Cartier for the present election, for which voting is fixed for October 29, 1973.Québec.Octobers, 1973.François Drouin.Chief Returning-Officer, 53970-u Judge of the Provincial Court.Notice concerning a publicity agency (section 377) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Conceptat Inc.\", 1500 Stanley Street, Room 408, Slontrcal, is recognized as the authorized agent of Sir.Claude-M.Gcncst, official agent of Mr.Jean-Guy Murphy.Parti Québécois candidate in the electoral district of Laprairie for the present election, for which voting is fixed for October 29.1973.Québec, October 8, 1973.François Drouin, Chief Returning-Officer, 53970-o Judge of the Provincial Court.Kc turning-Officer According to the presciiptions of paragraph 1 of section 14 of the Quéliec election Act, I have appointed, to fill the office of Returning-officer, the person whose name follows: District electoral Nom, pronoms Profession ou occupation Domicile Electoral district Same, christian names Profession or calling Domicile Kobert Baldwin.Hooper, Arthur (2).Rentier \u2014 Retired.Pierrefonds (2) En remplacement de monsieur Paul N.Lord, démissionnaire.\u2014 In place of Mr.Paul N.Lord, resigner.Québec, le 8 octobre 1973.Québec, October 8, 1973./.orté ù 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 880,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excellent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans It-present avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 novembre 1993.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.year.The raie of interest may lie the same for the whole issue; however, should more than one rati- be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from November 15.1973, Iteileiiipliim lahle - SlJOIhSOO \u2014 20 year.* Date Capital 15 || 1984 838.000 15 11 1985 .42.000 15 II 1986 45.000 15 II 1987 49.000 15 II 1988 .88.000 15 II 1989 .58.000 15 II 1990 .02,000 15 II 1991 .08.000 15 II 1992.73.000 15 II 1993 .80,001) The Taillon School Hoard, in conformity with section I of the Act to amend the School Hoard (irunts Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Kill 04).will request the minister of P.ducatioii to di posit in trust, with the M:.lister of Finance, from the grants to be awarded annually l>y him to tile said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if requited.Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.I to 10-year serial bonds with the lialancc carried forward to the tenth year.2.I to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.I to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.I to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $80,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of November 15, 1993.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue onl\\.and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be male according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, no 11 5919 Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas racbctnbles par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 880,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 novembre de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La Commission scolaire de Taillon s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 novembre 1973 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 3 avril 1963 \u2014 8276.000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 23 mai 1973 \u2014 8820,000 \u2014 construction de l'école Laurent Benoît; 30 mai 1973 \u2014 813,500 \u2014 frais de refinancement.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mercredi, le 31 octobre 1973, à 8 heures du soir.École Charles Lemoyne, 2525, rue Codcrrc, Saint-Hubert, Comté de Taillon, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Hubert (Comté de Taillon), ce 4 octobre 1973.Le directeur-général.Normand Pesant.Bureau Administratif, 2505, rue Codcrrc, Saint-Hubert, Comté de Taillon.P.Q.Téléphone: 67S-3150, code 514.53963-0 Cité de St-Hyacinthe Comté de St-Hyacinthe Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné lean-Paul Brault.greffier.Hôtel de Ville.1450, rue (iirouard.St-Hyacinthe.comté de St-Hyacinthe.P.Q.jusqu'à S heures du soir, mardi le 30 octobre 1973.pour l'achat île 82.247.500 d'obligations de la cité de St-Hyacinthe, comté de St-Hyacinthe.datées du 15 novembre 1973 et remboursables en série du 15 novembre 1974 au 15 novembre 1993 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 89c- \"> supérieur à 9%.payable semi-annuellemcnt les 15 mai et 15 novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission: cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présnt avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 novembre 1973.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than 880,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on November 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Taillon School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after November 15, 1973.without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: April 3, 1963 \u2014 8276.000 \u2014 loan renewal; Mav 23.1973 \u2014 8820,000 \u2014 construction of Laurent Benoît School; May 30.1973 \u2014 813,500 \u2014 refinancing costs.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Wednesday, October 31, 1973.at 8:00 o'clock p.m.at Charles l.cmoync School, 2525 Coderre Street, St.Hubert.County of Taillon.P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.St.Hubert (County of Taillon), October 4, 1973.NoiiMANi) Pesant, Director-General.Administration Office, 2505 Coderre Street, St.Hubert, Countv of Taillon.P.Q.Telephone: 678-3150.code 514.53963 City of St.Hyacinthe County of St.Hyacinthe Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, .lean-Paul Brault, City Clerk, at the City Hall.1450 (iirouar.l Street.St.Hyacinthe, County of St.Hyacinthe.P.Q., until 8:00 o'clock p.m.on Tuesday.October 30, 1973.for the purchase of a bond issue of 82.247.500 for the City of St.Hyacinthe.County of St.Hyacinthe, dated November 15, 1973.and redeemable serially from November 15.1974 to November 15.1993 inclusive, with interest at a rate of not less than S%, nor more than 9%.payable semianually on May 15th and November 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption tabic in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from November 15, 1973. 5920 QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, October 13.1073.Vol.105.So.it Tableau d'amortissement \u2014 $2,247.500 \u2014 20 ans Date Capital 15 11 1974.S 00.500 15 11 1975 .00.000 15 11 1970 .71.000 15 II 1977.77.000 15 II 1978.«.000 15 11 1979.90.000 15 11 1980.90.000 15 11 1981.102.000 15 11 1982.111.000 15 11 1983.120.000 Eu plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2\" Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant eu série I à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.46 Obligations échéant en série I à 10 ans uvec le solde reporté à 10 ans ]>our une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant a terme fixe 20 uns ne devront pas être pour un montant inférieur il $187.000.et si supérieur A ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 novembre 1993.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul îles modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Ontario.Lesdites obligations ne seront pas raehctables par anticipation sauf si elles sont émises eu partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $187.000.et seul cet excédent sera rachctahlc par anticipation au pair le 15 novembre de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La cité de St-Hyacinthe s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 novembre 1973 sans une autorisaton écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Rédemption table \u2014 $-2:217,500 \u2014 20 yearx Date Capital 15 11 1984.* 97.000 15 11 1985.104,000 15 11 1980.H2.000 15 II 1987.121.000 15 II 1988 .130.000 15 11 1989.138.000 15 II 1990.149.000 15 11 1991 .160.000 15 11 1992.173.000 15 II 1993.187,000 Moreover, the following terms and conditions only will he considered: 1.I to 10-ycar serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.I to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.I to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-ycar serial bonds with I lie balance carried forward to ten years for tin one part and the other part as 20-ycar fixed-term bonds.However, in the case of the last method of puymelit, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $187.000 and if greater than the latter amount, the said surplus nliotild only comprise one or several complete annual redemptions, hiking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of r, lemption excluding tin* maturity of Novcmlier 15.1993.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his telidei.covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of the said bank in Toronto.Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $187.000.and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par.on November 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of St.Hyacinthe agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after November 15.1073 without written authorization from the successful tenderer of the present issue. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÊIIEC, 13 octobre 1973, 105' année.,,° J,l 5921 Lesdites obligations seront émises en vertu îles règlements suivants: 927 \u2014 S44G.500 \u2014 aqueduc et égouts; 944 \u2014 $250.000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie, éclairage, achat de terrain et services récréatifs et communautaires; 947 \u2014 $1.410,000 ¦\u2014 aqueduc, égouts.voirie, etc.; 953 \u2014$120.000 \u2014 achat de terrains pour fins industrielles; 957 \u2014 $21,000 \u2014 achat de terrains pour fins industrielles.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à S heures du soir, mardi, le 30 octobre 1973.Hotel de Ville.1450.rue (iirouard.St-Hyacinthe, comté de St-Hyaciuthe.P.Q.\\/e conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Hyacinthe (Comté de St-Hyacinthc), ce 9 octobre 1973.Le greffier.Ikax-Paii, TSkai'i.t.Hôtel de Ville.1450, rue (iirouard.St-Hyacinthc.(St-Hyacinthc).P.Q.Téléphone: 773-2507.code 514.53992-d Ville de Baic-d'Urfc Comté lie Pointe-Claire Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations» seront reçues par la soussignée Madame Alice Hopgood, sccrétairc-trésorièrc.Hôtel de Ville.20410, I.akcshorc Road.Baic-d'Url'é.comté de Pointe-Claire, P.Q., jusqu'à 7.30 heures du soir, mardi, le 30 octobre 1973, pour l'achat, de $842,000 d'obligations de la ville de Baie-d'Urfé, comté de Pointe-Claire, datées du 15 novembre 1973 et remboursables en série du 15 novembre 1974 au 15 novembre 1993 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annucl-lement les 15 mai et 15 novembre de chaque année.l.c taux d'intéiét peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 novembre 1973.Tableau d'amortissement \u2014 $842.000 \u2014 20 ans Date Capital 15 11 1974.S 8,000 15 11 1975.9,000 15 11 1976.10,000 15 11 1977.11.000 15 11 1978.12,000 15 11 1979.13,000 15 11 1980.14,000 15 11 1981 .15,000 15 11 1982.16,000 15 11 1983.18,000 The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 927 \u2014 $446.500 \u2014 waterworks and sewers; 944 \u2014 $250.000 \u2014 waterworks, sewers, roads, lighting, purchase of land, recreational and community services; 947 \u2014 81.410,000 \u2014 waterworks, sewers, roads, etc.; 953 \u2014 8120.000 \u2014 purchase of land for industrial purposes; 957 \u2014 $21.000 \u2014 purchase of land for industrial purposes.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held at 8:00 o'clock p.m., on Tuesday.October 30.1973.at the City Hall.1450 (Iirouard Street, St.Hvacinthc, County of St.Hyacinthe.P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St.Hvacinthc (County of St.Hvacinthc), October 9, 1973.Ikax-Paui.BltAlxt, City Clerk, City Hall, 1450 (iirouard Street, St.Hvacinthc.(St.Hyacinthe), P.Q., Telephone: 773-2507, code 514.53992 Town of Baie-d'Urfc County of Pointe-Claire Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned.Mrs.Alice Hopgood, Secretary-Treasurer, at the Town Hall, 20410 Lakeshore Road, Baie-d'Urfé, County of Pointe-Claire, P.Q.until 7:30 o'clock p.m., on Tuesday, October 30, 1973, for the purchase of a bond issue of 8842,000 for the Town of Baie-d'Urfé, County of Pointe-Claire, dated November 15, 1973, and redeemable serially from November 15, 1974 to November 15, 1993 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on May 15th and November 15th of each year.The rate of interest may be the same of the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from November 15, 1973.Redemtion table \u2014 $812,000 \u2014 20 years Date Capital 15 11 1984.819,000 15 11 1985.21,000 15 11 1986.23,000 15 11 1987.25,000 15 11 1988.28,000 15 11 1989.30,000 15 11 1990.33,000 15 11 1991.35,000 15 11 1992.39,000 15 11 1993 .463,000 5922 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.October 13.107.1.Vol.10n.So.il En plus, lu modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série I à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième unnéc.3° Obligations échéant en série I à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série I à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $60,000.et si supérieui à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 novembre 2003 de la partie renouvelable ci-après Indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour nu seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées, L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 novembre 1993 an montant de $403.000 comprend un solde de §421.000 renouvelable pour une période edditionncllc de 10 ans.et échéant connue suit : \tDate\tCapital 15\t11 l»04\t82S.000 13\t11 1995.\t.30.000 15\tIl 1990\t.33.000 15\tIl 1997 .\t.30.000 15\t11 199N\t.39.000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lien, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à tontes les succursales dans la province de Québec de la hunqui dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite lianqur â Toronto.Ontario.Lesdites obligations ne seront pas raehclaldes par anticipation sauf si elles sont émises en partie ù terme fixe 20 ans pour un moulant supérieur à $403.000 et seul cet excédent sera nichelalile par anticipation au | air le 15 iioveinbie de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de I émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devin être accompagiiée d'un chèque visé égal a l%dn montant de l'emprunt, Lu ville de Haic-dTrfé s'engage à Ile pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans le, les soixante jours à compter du 15 novembre 1973 sans une autorisation écrite lie l'adjudicataire de la présente émission.Moreover, the following terms and conditions only will he considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to llie fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-ycar serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $60,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of November 15, 2003 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of tin-above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of November 15.1993 in the amount of $463.000 includes a balance of $421,000 renewable for an additional 10-ycar period, maturing us follows: \tDale\tCapital 15\t11 1999.\t.$43,000 15\t11 2000.\t.46.000 15\t11 2001.\t.51.000 15\t11 2002.\t.55,000 15\t11 2003.\t.60.000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bunk mentioned in the loan procedure and at the head office of the said Wank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they arc issued partly as 20-ycar fixed-term bonds for an amount greater than $463.000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par.on November 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Kach tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.I he Town of llaie-d'lifé agrees not to bring out new lionds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after November 15, 1973, without written authorization from the successful tenderer of the present issue. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1973, 105' année, n° Al 5923 lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 482 \u2014 $32,000 \u2014 aqueduc et égouts; 483 \u2014 $544,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 484 \u2014 $100,000 \u2014 voirie; 4S5 \u2014 $166.000 \u2014 voirie.l>es soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 7.30 heures du soir, mardi, le 30 octobre 1973.Hotel de Ville, 20410, Lakeshore Road, Baie-d'Urfé, comté de Pointe-Claire, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni le plus haute ni aucune des soumissions.Baie-d'Urfé (Comté de Pointe-Claire), ce 3 octobre 1973.La secrétairc-trésorière.Madame Alice Hopooou.Hôtel de Ville, 20410.Lakeshore Road.Baie-d'Urfé (Comté de Pointe-Claire).P.Q.Téléphone: 457-5324, code 514.53991-o Ville de Charlemagne Comté de L'Assomption Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations i seront reçues par le soussigné Léo M.Lepage, secrétaire-trésorier.Hôtel de Ville, 82, rue Sacré-Coeur, Charlemagne, comté de l'Assomption.P.Q.I5Z-1WS.jusqu'à 8 heures du soir, mercredi, le 31 octobre 1973.pour l'achat de $155.000 d'obligations de la ville de Charlemagne, comté de L'Assomption, datée du 15 novembre 1973 et remboursables en série du 15 novembre 1974 au 15 novembre 1993 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à N%, ni supérieur à 9%, payable se mi-annuellement les 15 mai et 15 novembre de chaque année.Le taux d'intérêt l>eut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 novembre 1973.Tableau d'amortissement \u2014 $155,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 11 1974 .8 1,500 15 11 1975 .2.000 15 11 1976 .2,000 15 11 1977 .2.000 15 11 1978 .3.000 15 11 1979 .3.000 15 11 1980 .3,500 15 11 19S1.3,500 15 11 19S2.4,500 15 11 19S3.4,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde re|x>rté ù la dixième année.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 482 \u2014 $32,000 \u2014 waterworks and sewers; 483 \u2014 $544,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 484 \u2014 $100.000 \u2014 roads; 485 \u2014 $166,000 \u2014 roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held at 7:30 o'clock p.m., on Tuesday, October 30, 1973, at the Town Hall, 20410 Lakeshore Road, llaie-d'Urfé, County of Pointe-Claire, P.Q.The Council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Baie-d'Urfé (County of Pointe-Claire), October 3, 1973.Mrs.Alice Hohcooo, Secretary-Treasurer.Town Hall, 20410 Lakeshore Road.Baie-d'Urfé (Countv of Pointe-Claire), P.Q.Telephone: 457-5324, code 514.53991 To«n of Charlemagne County of L'Assomption Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned.Léo M.Lepage, Secretary-Treasurer, at the Town Hnll.82 Sacré-Coeur Street.Charlemagne, County of L'Assomption.P.Q.I5Z-1WS, until S:00 o'clock p.m.on Wednesday, October 31, 1973.for the purchase of a bond issue of $155,000 for the Town of Charlemagne.County of L'Assomption, dated November 15.1973 and redeemable serially fiom November 15.1974 to Novembei 15.1993 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%.nor more than 9%, payable semiannually on May 15th anil November loth of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue: however, should more than one rate be used, the amount issued at each différent iatc must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from November 15.1973.Redemption Table \u2014 -SI55,000 \u2014 20 years \tDal\t,c\tCapital 15\t11\t\t 15\til\t1985 .\t.4.000 15\tLI\t1986 .\t.4.500 15\t11\t1987 .\t.5.000 15\t11\t19S8.\t.5.500 15\t11\t1989 .\t.5.500 15\t11\t1990 .\t.6.000 15\t11\t1991 .\t.6.000 15\t11\t1992 .\t.6,500 15\t11\t1993 .\t.79,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance canied forward to the tenth year. 5924 quriiec official (iaxktti.Ortnlirr 11.1079, I'd.108, So.11 2° Obligations échéant on série I à 15 uns avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 uns avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série I à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $9.000.et si supérieur à ce dernier montant, cet excellent ne devra comprendre qu'un ou îles amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le present avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance au 15 novembre 2003 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des inodes d'émission ci-haut et no devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.I.'adjudication sera faite conformément à la loi.1,'échéancc du 15 novembre 1993 au montant de $79.000 comprend un solde de $72.000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans.et échéant comme suit: \tDate\tCapital 15\tIl 1994 .\t$ 5.500 15\t11 1995.\t.0.000 l.-.\t11 1990 .\t.0.500 i:,\t11 1997 .\t.0.500 L\".\t11 1998.\t.7.000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, pai chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachotablos par anticipation sauf si elles sont émises on partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $79.0(X).et seul cet excédent sera rachetai)le par anticipation au pair le 15 novembre de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.I-a ville de Charlemagne s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 novembre 1973 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.I
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.