Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 9 (no 10)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1974-03-09, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC PARTIE 1 AVIS JURIDIQUES OFFICIAL GAZETTE PART 1 JURIDICAL NOTICES 9 MARS 1974 N° 10 1901 ft\\l E & & 3/ Pr?e 1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 mars 1971.106' année, n° 10 1903 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general cliaracter, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas.l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazelle officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, a moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than onoe, In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documentsibecausc of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Officiai PublUher 1904 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE March 9.197A, Vol.106, No.10 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: S5 des 100 mots.Exemplaire séparé: 81 chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1 ) : du 1er janvier au 31 décembre.$20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publics une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Editeur officiel du Québec.Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire.Québec.25 oetobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1 ) : from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings.Québec, October 25, 1972.Pour toute demande renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazelle officielle du Québec-, veuillez communiquer avec: Georges Lapicrre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Editeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1A 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapicrre Québec Official Gazelle Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mar, MA, 106' année, n° 10 1905 AVIS JURIDIQUES\tJURIDICAL NOTICES Ministère des institutions\tDepartment of Financial financières, compagnies\tInstitutions, Companies et coopératives\tand Cooperatives Lettres patentes ( I\" partie) Letters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Norn / Name Siège social / Head Office Incorporation Date A.D.M.CONSTRUCTION INC____ CONSTRUCTION A.D.M.INC.ACADO LTEE.ACIER PROFILE S.B.B.INC.S.B.B.FORMED STEEL INC.ACOUSTIQUES BERNA INC.AGENCE DE SECURITE MAURICE INC.MAURICE SECURITY AGENCY INC.AGENCES MARINES MONARCH INC.MONARCH MARINE AGENCIES INC.AGRAFES DORSON LIMITEE .DORSON STAPLES LIMITED.ALUMINIUM MIRABEL INC.MIRABEL ALUMINUM INC.LES AMENAGEMENTS LE COMPLEXE LTEE COMPLEX DEVELOPMENTS LTD.AMEUBLEMENT & DECOR N.MARTIN INC.AMEUBLEMENT FLOYD INC.FLOYD FURNITURE INC.AMEUBLEMENTS LISE MONTPETIT INC.LES APPARTEMENTS ST-YVES INC.ARNOLDI TOOL AND DIE INC.MATRICES ET OUTILS ARNOLDI INC.ASSURANCES COTE & DIONNE INC.B.de E.CARTAGE {QUEBEC) LTD.SERVICE DE TRANSPORT B.& E (QUEBEC) LTEE B.T.R.TRANSPORT INC.TRANSPORT B.T.R.INC.BARTHOM FASHIONS INC.LES MODES BARTHOM INC.MAX BEAUVAIS LIMITEE.507.Place d'Armes, suite 1209.Montréal 299.boulevard Maple Grove, Maple Grove.108, Bord-de-l'Eau, Sainte-Dorothée Montréal.778.Ile Avenue, Thetford Mines.Québec.Montréal.357.boulevard Sauvé.Place St-Eusta-che, suite 105, Saint-Eustache.Montreal.2700, Papineau.Longueuil.18, rue St-Pierre, Saint-Constant Montreal.Montreal.3637 Métropolitain Boulevard East, Room 301, Montreal 456.Rivière-du-Loup.8577 Pascal-Gagnon, Saint-Léonard Montréal.Sorel.Montréal.16 01 74 22 01 74 17 12 73 07 12 73 11 09 73 20 12 73 Il 01 74 14 01 74 16 11 73 04 01 74 17 01 74 05' 12 73 28 Cl 74 13 12 73 17 01 74 19 12 73 14 Ul 74 06 02 74 25 01 74 1906 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 9, 1971.Vol.106.No.10 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date MADELEINE BEDARD INC.MARCEL BELISLE INC.BETON DU NORD LTEE.BEUTBL.GOODMAN LTEE\tEXCEL FOOTWEAR MFC.CO.LTD.\t15\t06\t69 \tJEAN-CLAUDE LABRECQUE INC.\t18\t07\t67 LES INDUSTRIES B.M.S.LTEE.B.M.S.INDUSTRIES LTD.\tLES IMMEUBLES ST-LOUIS LTEE ST-LOUIS REALTIES LTD.\t:ii\t08\t00 JONICA SOLEX TRAVEL AGENCY LTD.AGENCE DE VOYAGES SOLEX JONICA LTEE\tJONICA TRAVEL AGENCY LTD.L'AGENCE DE VOYAGE JONICA LTEE\t0»\t09\t69 KAREN BABEL INC.\tKEREN BABBLE INC.\t29\t04\t72 LILIANNE LAVAL LIMITEE.\tNADELLE INC.\t21\t07\t33 LOUSEL INC.\tLOU SELTZER AGENCIES INC.\t02\t04\t03 MANOIR VIEILLE GRANGE SENTINELLE DU PARC INC.\tCAMPING SENTINELLE DU PARC INC.\t18\t09\t73 LES MINES GOLDCOP LIMITEE.\tGOLDCOP MINES LIMITED.\t15\t06\t71 GOLDCOP MINES LIMITED\t(No personal liability)\t\t\t MOUNTAIN ACRES GOLF * SKI CLUB.CLUB DE GOLF ET DE SKI « MOUNTAIN ACRES »\tMOUNTAIN ACRES GOLF CLUB.\t02\t07\t68 SCIERIE CARRIERE LTEE.CARRIERE SAW-MILLS LTD.\tBROWNSBURG LUMBER LIMITED LA CIE DE BOIS DE BROWNSBURG LTEE\t29\t08\t45 \tMATINEE DRESS INC.\t27\t11\t57 INTEGRATED MARINE SYSTEMS I.M.S.INC.\tCATHELCO SYSTEMS (QUEBEC) LTD.\t22\t02\t57 LES VENTES VILLE MARIE LIMITEE.VILLE MARIE SALES LIMITED\tALIMENTS VILLE MARIE LIMITEE VILLE MARIE FOODS LIMITED\t20\t06\t61 Y.N.L.ENTERPRISES LTD.LES ENTREPRISES Y.N.L.LTEE\tMONTREAL CREDIT JEWELLERS (QUEBEC) INC.\t31\t07\t68 56272-o Le directeur du service des compagnies.Pierre Desjardins.56272-0 Pierre Debjardins, Director of the Companies Service. 1916 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9.1971, Vol.106, No.10 Abandon de charte\tSurrender of Charter Le ministre ries institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies.U a accepté l'abandon de la charte de:\tThe Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has accepted the surrender of the charter of Nom / Name\tIncorporation Dissolution Date Date ALLIANCE ADVERTISING 4 APPLIED ARTS INC.ANDY MAX LIMITED.JEAN FAITOUT LIMITEE ASTOR ARMS APARTMENTS INC.C.B.F.INVESTMENT CORPORATION.CLAREN AUTO RACING INC.CLOVER SALES INC.C.CLOUTIER INC.CONTROL EQUIPMENT CO.LTD.LES COURTIERS D'ASSURANCE DE DUVERNAY INC.DAVENO UPHOLSTERING LTD.ENTERPRISE AGENCIES LIMITED.FARGO DRESS CO.INC.FIBRELITE INC.GOUBAUD DE PARIS (QUEBEC) INC.FRANK LAPAN LIMITED.MANIK HOLDINGS INC.McNEIL 4 COULSON (CANADA) LTD.MEEHAN 4 YOUNG CO.LIMITED.MONICO INC.MORIN HEIGHTS HOLDINGS INC.PROFESSIONAL NUMISMATIC COIN CO.R.T.A.INC.RAPID GAZ BAR INC.RELIABLE INVESTMENT INC.RIDDELL ESTATES LIMITED.LA SOCIETE CIVIQUE DE PLACEMENTS LTEE.THE CIVIC SOCIETY OF INVESTMENTS LTD.R.THOUIN LTEE.WESTSIDE APARTMENTS LTD.27\tM\t49\t01\t03\t74 21\t08\t58\t01\t03\t74 07\t02\tII\t01\t09\t74 10\t09\t68\t01\t03\t74 IT\t06\t70\t01\t03\t74 10\t01\t55\t01\t03\t74 M\t10\t58\t01\t03\t74 14\tOS\t63\t01\t04\t71 n\t11\t64\t01\t04\t74 i.i\t10\t66\t01\t01\t74 10\t01\t42\t01\t04\t74 17\t08\tso\t01\t03\t74 26\t04\tOK\t01\t03\t74 11\t12\t68\t01\t03\t74 02\t09\t25\t01\t03\t74 02\t10\t07\t01\t03\t74 19\t09\t58\t01\t0.3\t74 23\t10\t45\t01\t03\t74 29\t04\t60\t01\t0-1\t74 M\tOB\t01\t01\t03\t74 OS\t07\t69\t01\t01\t74 18\t02\t69\t01\t03\t74 07\t01\t71\t01\t0.3\t74 26\t01\t60\t01\t03\t74 90\t11\t63\t01\t03\t74 26\t10\t63\t01\t03\t74 17\t10\t68\t01\t03\t74 19\t08\t69\t01\t03\t74 56272-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.50272-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 10fi' année, n\" 10 1917 Fusion de compagnies Amalgamation of companies Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes autorisant la fusion de: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted letters patent authorizing the amalgamation of: Nom de la nouvelle compagnie Name of new company Siège social Head office Fusion Amalgamation Date Nom des compagnies fusionnées Names of companies amalgamated BETON PROVINCIAL LTEE LES MEUBLES RADISSON (QUEBEC) LIMITEE RADISSON FURNITURE (QUEBEC) LIMITED 687, rue D'Amours, Matane.Suite 4125, 1 Place Ville Marie, Montréal.31 12 73 BETON PROVINCIAL LTEE.BETON PROVINCIAL (BAIE DES CHALEURS) LIMITEE BETON PROVINCIAL (HAUTE-RIVE) LIMITEE 31 12 73 E.THIBAULT LIMITEE \u2014 E.THIBAULT LIMITED MARIUS OUELLET LIMITEE ROYAL CHESTERFIELD INC.56272-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.56272-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Lettres patentes supplémentaires Supplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a accordé des lettres patentes supplémentaires à: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes L'ASSOCIATION DES CHEMINS D'HIVER 07 02 48 DE ROUYN-NORANDA RAYMOND BERN 1ER AUTO INC.16 10 61 AUTOMOBILES RAYMOND BERNIER INC.BOUCHERIE DE FRANCE INC.05 11 70 NAPOLEON BROCHU INC.03 09 71 CHARLAND AVE.IRON WORKS COMPANY 26 01 60 LTD.CLUB DE GOLF LE ST-LAURENT INC.02 12 70 ST.LAWRENCE GOLF CLUB INC.COMCAP FACTORS INC.25 05 73 LES FACTEURS COMCAP INC.THE DOMINION COMB AND NOVELTY 30 07 03 COMPANY EPICERIE LATINA INC.18 04 67 LATIN A GROCERY INC.14 01 74 Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 28 01 74 1) Ancien nom / Former name: PAQUET & BERNIER AUTO INC.2) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the Utters patent 28 01 74 Modifiant les dispositions des lettres patentes/ -4mending the provisions of the letters patent 11 02 74 Etendant les pouvoirs / Extending the powers 28 01 74 Modifiant les dispositions des lettres patentes/ A mending the provisions of the letters patent 10 12 73 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 28 12 73 Modifiant le capital / Altering the capital 29 01 74 Modifiant le capitalAltering the capital 28 01 74 Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters patent 1918 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1971, Vol.10G, No.10 Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes FABRICANT DE ROULETTES DURABLES LIMITEE DURABLE CASTERS AND WHEELS MANUFACTURER LIMITED LA FERME WILSON INC.01 08 63 GILBEC INC.05 07 73 HOPITAL ST-LAMBERT (CONVALESCENTS) 16 03 59 L'INDUSTRIELLE-SERVICES TECHNIQUES 03 04 67 INC.INDUSTRIAL LIFE - TECHNICAL SERVICES INC.KIPAWA AIR SERVICE INC.02 06 66 MACHINERIE DRUMMOND INC.14 04 69 LA MAISON DE LA PIZZA & DU SPA- 21 02 73 GHETTI NATALINO INC.NATALINO'S PIZZA & SPAGHETTI HOUSE INC.MENUISERIE EVEREST LTEE.27 07 72 EVEREST WOODWORKS LTD.01 06 73 12 12 73 Modifiant le capital / Altering the capital NATIONAL LASER PRODUCTS LTD.\t18\t08\t67\t10\t08\t78 LES PAVAGES DE BEAUCE LIMITEE.\t07\t05\t64\t13\t12\t73 PIZZA PITSAS LIMITEE.PITSAS PIZZA LIMITED\t03\t06\t71\t06\t11\t73 LES PLACEMENTS CARISA INC.\t15\t12\t72\t02\t11\t73 PLACEMENTS LA RONDELLE LTEE\t23\t12\t71\t28\t11\t73 S.A.F.EQUIPEMENT INC.S.A.F.EQUIPMENT INC.\t17\t06\t53\t22\t01\t74 SOCIETY OF THE DIVINE WORD.SOCIETE DU VERBE DIVIN\t12\t01\t49\t16\t11\t73 Sr.JOHNS EXPRESS LIMITED.L'EXPRESS ST-JEAN.LIMITEE\t26\t06\t41\t20\t12\t73 LES TEXTILES DU GRAND MOULIN, INC.\t01\t04\t49\t28\t11\t73 VITRERIE CHAMPLAIN (1969) INC.\t22\t07\t69\t04\t02\t74 CHAMPLAIN GLASS (1969) INC.08 01 74 Modifiant le capital / Altering the capital 15 11 73 Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent 30 01 74 Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 15 01 74 Etendant les pouvoirs f Extending the powers 07 12 73 Modifiant le capital / Altering the capital 17 12 73 Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 22 11 73 Ancien nom / Former name: SINO ALONG SAM PIZZA INC.PIZZA SAM CHANTONS EN CHOEUR INC.19 02 73 Ancien nom / Former name: A.G.INTERNATIONAL IM PORT & MFG.CO.INC.COMPAGNIE INTERNATIONALE D'IMPORTATION ET DE FABRICATION A.G.INC.powers 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Etendant les pouvoirs / Extending the powers GOLDEN B.B.Q.PLACE INC.lodifiant le capital / Altering the capital lodifiant le capital / Altering the capital vncien nom / Former name: S.A.F.CONSTRUCTION INC.lodifiant la valeur des biens immobiliers ' Modifying the value of immoveable property patentes / Amending certain provisions of the letters patent patentes / A mending certain provisions of the Utters patent tentes / Amending the provisions of the letters patent 56272-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.56272-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 1919 Commission des transports du Québec Québec Transport Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante : I \u2014 Avis de la Commission < proprio motu > (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées.i.membre siégeant seul.\u2014 transport générai de personnes.\u2014 transport général de choses.¦\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). 1920 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1971, Vol.106, No.10 ii.au moins troi9 membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) vérification de permis annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.* permis spéciaux.(0 M) (e) ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).Verification of permits.Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.* Special permits.* Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.II \u2014 Avis d'introduction de requête : La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.* In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.II \u2014 Notice of submission of application : The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.Rôle Q-0818 Q-200668 FERNAND BEGIN, 7555, 3e Avenue Ouest.Charlesbourg.Rôle Q-0819 Q-201922 EMILE BARIL, 1153 Ste-Angèle, Trois-Rivières.Rôle Q-0820 7510-V-D-2 7737-V-D-2 MAURICE PRESSE.Fortierville, Cté Lotbinicre et / and BELLECHASSE TRANSPORT INC., 3600, boul.Hamel, Québec 8.Rôle Q-0821 6698-V-D-l 22358-V-D-l ARMAND McMAHON, Ste-Monique, Cté de Nicolet et 1 and MAURICE McMAHON, R.R.1, Grand St-Esprit.Cté de Nicolet.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Joseph Denault portant le No Q-200669.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Paul Perron portant le No Q-200552.Cession de la propriété du système de transport, clauses c et d, (vente).Maurice Pressé demande l'autorisation de céder à Bellechasse Transport Inc., 7737-V, 3600, boul.Hamel, Québec 8, la propriété du système de transport des clauses c et d du permis No 7510-V qui se lisent comme suit: c) Transport général - longue distance -route restreinte - c) De Ste-Emélie et Fortierville à Trois-Rivières, et retour.d) Transport général - longue distance -route restreinte - d) De Ste-Emélie et Fortierville.Parisville.Val-Alain, Villeroy et Ste-Françoise à Québec, et retour.Cession de la propriété du système de transport (vente).t Armand McMahon demande l'autorisation de céder à: Maurice McMahon, (22358-V) R.R.1, Grand St-Esprit, cté de Nicolet, la propriété du système de transport suivant: Permis No 6698-V: Transport général - service local - 8te-Monique et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites dudit endroit; Transport général - service longue distance - rayon - De Ste-Monique à tous les endroits situés dans un rayon de 30 millea et retour; The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate held bv Mr.Joseph Denault, bearing No.Q-200669.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate held by Mr.Paul Perron, bearing No.Q-200552.Transfer of clauses c and d of the ownership of a transport service (sale).Maurice Pressé requests authorization to transfer to: Bellechasse Transport Inc., 7737-V.3600 Hamel Blvd., Québec 8, the ownership of clauses c and d of the transport service, permit No.7510-V, which read as follows: (c) General trucking - long distance - restricted route - (c) From Ste.Emélie and Fortierville to Trois-Rivières, and return.(d) General trucking - long distance - restricted route - (rf) From Ste.Emélie, Fortierville, Parisville, Val-Alain, Villeroy and Ste.Françoise to Québec, and return.Transfer of ownership of a transport service (sale).Armand McMahon requests authorization to transfer to: Maurice McMahon, (22358-V) R.R.1.Grand St.Esprit, County of Nicolet, the ownership of the following transport service: Permit No.6698-V: General trucking - local service - Ste.Monique and any point located over a distance of not more than five miles from the limits of said locality: General trucking - long distance service -radius - From Ste.Monique to any point located within n 30-mile radius and return; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1971, 106' année, n° 10 1921 Transport général - service longue distance - route restreinte - irrégulier - De Ste-Monique à Montréal et retour pour le transport de marchandises destinées à Ste-Monique ou en provenant.General trucking - long distance service -restricted route - irregular - From Ste.Monique to Montreal and return for the transportation of goods originating from or destined to Ste.Monique.Rôle Q-0822 18627-V-D-5 TRANSOL INC., 124 rue St-Pierre, Québec 2.Que.Modification de permis.La partie requérante, détentrice d'un permis de transport dont la clause d se lit: Transport restreint-longue distance-route restreinte - contrat - régulier - Entre les gares de la Cie des Chemins de Fer Nationaux du Canada à Rivière-du-Loup, Chemin du Lac, St-Alexandre, St-Pascal, St-Philippe-de-Néri, Rivière-Ouelle, St-Pacôme, Ste-Anne, Ste-Louise, St-Jean-Port-Joli, l'Is-letville.ainsi qu'aux résidences des agents de la Cie des Chemins de Fer Nationaux du Canada à Andréville et Ste-Hélène, et retour, pour le transport quotidien (sauf les dimanches et jours de fête) de marchandises pour le compte de la Cie des Chemins de Fer Nationaux du Canada.Demande que la susdite clause soit modifiée pour qu'elle se lise, a l'avenir comme suit: Transport restreint-longue distance-route restreinte - contrat - régulier - Entre les gares de la Cie des Chemins de Fer Nationaux du Canada à Rivière-du-Loup, Chemin-du-Lac.St-Alexandre, St-Pascal, St-Philippe-de-Néri, Rivière-Ouelle, St-Pacôme, Ste-Anne, Ste-Louise, St-Jean-Port-Joli, l'Isletville et Monk ainsi qu'aux résidences des agents de la Cie des Chemins de Fer Nationaux du Canada à Andréville, Ste-Hélène et Ste-Perpétue, et retour, pour le transport quotidien (sauf les dimanches et jours de féte) de marchandises pour le compte de la Cie des Chemins de Fer Nationaux du Canada.Modification of permit.The applicant holding a transport permit in which clause d reads as follows: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - regular - Between the Canadian National Railways stations located in Rivière-du-Loup, Chemin-du-Lac, St.Alexandre.St.Pascal, St.Phi-lippe-de-Néri, Rivière-Ouelle, St.PacÔme, Ste.Anne, Ste.Louise.St.Jean-Port^Joli.l'lsletville, and to the homes of the agents of the Canadian National Railways in André-ville and Ste.Hélène, and return, for the daily (save Sundays and legal holidays) transportation of goods on behalf of the Canadian National Railways.Requests that the aforesaid clause ce modified to read henceforth as follows: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - regular - Between the Canadian National Railways stations located in Rivière-du-Loup, Che-min-du-Lac.St.Alexandre, St.Pascal, St.Philippe-de-Néri, Rivière-Ouelle, St.PacÔme, Ste.Anne, Ste.Louise, St.Jean-Port-Joli, l'lsletville and Monk, and to the homes of the agents of the Canadian National Railways in Andréville, Ste.Hélène and Ste.Perpétue, and return, for the daily (save Sundays and legal holidays) transportation of goods on behalf of the Canadian National Railways.Rôle Q-0823 Q-201932 wi lb rod gagné, 1058 boul.Blanche, Hauterive, Cté Saguenay.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Darius Thibeault portant le No Q-201928.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate held by Mr.Darius Thiheault, bearing No.Q-201928.Rôle Q-0824 1467-V-D-4 TRANSPORT FRENETTE INC., 251 rue Principale, Notre-Dame-de-Portneuf, Cté de Portneuf.Modification de permis (droit additionnel).La partie requérante demande à la Commission d'ajouter à son permis l'autorisation suivante: Droit additionnel: La détentrice est autorisée à louer, à long terme, (5 ans), d'IAC Limitée \u2014 IAC Limited, permis 508-DYV, quatre (4) châssis à « containers » et deux (2) trains d'accouplement dont la description, apparaissant au contrat de location déposé à la Commission, est la suivante: Châssis à « containers o: Séries: 1901-1665-001 1901-1665-002 1901-1665-003 1901-1665-004 Trains d'accouplement: Séries: 1606-1744-001 1606-1744-002 Modification of permit (additional right).The applicant requests the Commission to add the following authorization to its permit: Additional right: The permit-holder is authorized to lease, on a long-term basis (5 years) from IAC Li-mitéee \u2014 IAC Limited, permit 608-DYV, four (4) container frames and two (2t coupled trains described as follows in the lease filed with the Commission: Container frames: Serial: 1901-1665-001 1901-1665-002 1901-1665-003 1901-1665-004 Coupled trains: Serial: 1606-1744-001 1606-1744-002 1922 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol 106, No.10 Rôle Q-0825 22685- V-D-4 23667-V-D-l ARRIMAGE ET SERVICE CARTIER INC.CARTIER STEVEDORING AND SERVICES INC., Case Postale 1576.Port-Cartier (Saguenay) et / and NAPOLÉON BROCHU INC., 360 avenue Noël, Sept-Iles (Saguenay) Rôle Q-0826 4732-V-D-2 GRENIER TRANSPORT INC., 298 avenue Chassé.Case Postale 700.Ste-Marie (Beauce).Rôle Q-0827 Q-500347 GILLES DUFOUR, 20 Bergeron, St-Honoré, Cté Dubuc, P.Q.Q-0828 Q-500547 CHARLES TREMBLAY, 19, rue St-Marcellin.Les Escoumins, Ct6 Saguenay, P.Q.Rôle Q-0830 Q-200440 HONORÉ THIBEAULT, 550, Commercial, St-David, Levis.Rôle Q-0831 Q-201943 GASTON GENDRON, Ste-Anne-des-Monta, Cté de Gaspé Ouest.Rôle M-1190 3556-A - (D.2) LES AUTOBUS ROLAND INC., 430, rue De Martignv, St-Jérôme.(Terrebonne), P.Q.Cession partielle de la propriété du système de transport (vente).Arrimage et service Cartier Inc.\u2014 Cartier Stevedoring and Services Inc.demande l'autorisation de céder à la compagnie: Napoléon Brochu Inc., 360 avenue Noël, Sept-Iles (Saguenay) la propriété du système de transport suivant: La clause c du permis de transport No 22685-V: Transport restreint - longue distance - territoire - fardier - A et entre tous les endroits situés dans un rayon de 50 milles de Port-Cartier, pour le transport, par semi-remorques ou par far-diers, de machinerie, machinerie lourde, équipement, équipement lourd ou objets qui, à cause de leur grosseur, forme ou pesanteur nécessitent l'usage d'équipement spécialisé et dont le chargement ou le déchargement nécessite l'usage de grue mécanique, le tout pour le public en général.Note: Ce permis sera sujet au permis de dimensions ou pesanteur du ministère des transports.Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis le service suivant: Transport restreint-longue distance-route restreinte - contrat - De Ste-Marie-de-Beauce à la frontière Québec-Etats-Unis (ports d'entrée: Jackman, Me.et Derby Line, Vt.) \u2014 destination: Fra-mingham, Mass.\u2014, pour le transport de produits finis manufacturés, et retour avec matières premières servant à leur fabrication, le tout pour le compte de Les Valises Scott Ltée.Région 2 12.13 Artisan Personne physique: Propriétaire d'un camion Mack 1974.No de série: R795ST3450.No d'immatriculation au Québec: X -13801-74.Région 9 12.13 Artisan Personne physique: Propriétaire d'un camion tracteur GMC-74 portant le No de série: 1DH924V563214, No d'immatriculation au Québec F-279913, devant tirer la remorque ou semi-remorque dont le No d'immatriculation est: R-283765.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Robert Roger portant le No Q-200439 D-2.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Edouard Deschênes portant le No Q-201942.La requérante demande d'être autorisée ù donner le service suivant: Classe de permis: Transport de passagers - autobus -Service : Service urbain dans la Cité de St-Jérôme et les Villes de St-Antoine et Lafontaine selon parcours - horaires et territoires suivants: Partial transfer of the ownership of a transport service (sale).Arrimage et Service Cartier Inc.\u2014 Car-tier Stevedoring and Services Inc.requests authorization to transfer to: Napoléon Brochu Inc.360 Noël Avenue, Sept-Iles.County of Saguenay.the ownership of the following transport service: Clause c of the trucking permit No.22685-V: Restricted trucking - long distance - territory - float - To and between any point located within a radius of 50 miles from Port-Cartier, for the transportation, by semi-trniler or float, of machinery, heavy machinery, equipment, heavy equipment of objects which, because of their size, shape of weight require the utilization of special equipment, and whose loading or unloading require the utilization of mechanical cranes, the whole for the public at large.Note: This permit is subject to the obtaining of a size or weight permit issued by the Department of Transport.Modification of permit.The applicant requests that the following service be added to its permit: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From Ste.Marie-de-Beauce to the Quebec-United States border (Pons of entry: Jackman, Me.and Derby Line.Vt.) \u2014 destination: Framingham, Mass., for the transportation of finished manufactured products, and return with raw materials utilized in their manufacturing, the whole on behalf of Les Valises Scott Ltée.Region 2 12.13 Artisan Physical person: Owner of a 1974 Mack truck.Serial number: R795ST3450.License number in the Province of Québec: X-13801-74.Region 9 Artisan Physical person: Owner of a 74/GMC tractor truck, bearing serial No.1DH924V563214.License No.in the Province of Québec: F-279913.to haul the trailer or semi-trailer bearing license No.R-283765.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate held by Mr.Robert Roger, bearing No.Q-20C439 D-2.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate held by Mr.Edouard Deschênes, bearing No.Q-201942.The applicant requests authorization to provide the following service: Class of permit: Transportation of passengers - Bus -Service: Urban service in the City of St.Jérôme and the Towns of St.Antoine and Lafontaine according to the following routes, timetables and territories: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106e année, n° 10 192.3 Rôle M-1191 3558-A- (D.l.) ROSAIRE BISSONNETTE, 153.me Malo.Beloeil.P.Que.Circuit St-Antoine: Service aux 30 minutes.Terminus départ Parent - Ste-Anne - Du Palais à gauche - Labelle à gauche - De Martigny à gauche - entrée chez Zeller's 9ième rue - 20ième à droite - Boul.St-An-toine à gauche - 24ième à droite - 22ième à droite - 19ième à droite - Boul.St-Antoine à gauche - Route 11 - à droite rue St-Georges -Parent à droite - et de là au terminus.Circuit Ste-Paule: Service aux 30 minutes.Terminus départ Parent - Ste-Anne - Du Palais à gauche - St-Georges à droite- Passer la lOOième rue - entrée Centre Lafontaine -I06ième à gauche - Route 11 - à gauche Centre d'Achat - entrée St-Jérôme - rue Labelle - Parent à gauche - et de là au terminus.Circuit Laviolette et Ste-Marcelle: Service à toutes les heures.Terminus départ par Parent - Ste-Anne -Du Palais à gauche - St-Georges à droite -Godmer à gauche - De Martigny à droite -Laviolette.Lajeunesse à gauche - Raymond à gauche - Bastien à droite - Nadon à droite - Bourassa à droite - Mgr Dubois à gauche - Paré à gauche - Gauthier à droite -\u2022Danis à gauche - Brière à droite - retour avant chez Pilon - Brière, Castonguay à droite - Labelle à droite - Legault à gauche -De Villemure à gauche - et de là au terminus.Circuit Domaine : Service à toutes les heures.Terminus départ par Parent - O'Shea à droite - Latour à gauche - 3ième Boulevard à droite - 7ième rue - 34ième à gauche -lOième à gauche - 37ième à gauche - Bran -3ième Boulevard à droite - Parent à gauche -Madeleine à droite - Filion à gauche - Tru-del - Fournier à gauche - Ouimet à gauche -Melançon à droite - Parent à droite - Ste-Anne à gauche - Legault à droite - De Villemure à droite - et de là au terminus.Tarifs: Adultes: $0.40 du billet $2.00 le livret de 6 billets $5.00 le livret de 15 billets Enfants: $0.20 du billet $1.00 le livret de 6 billets Horaires: Du lundi au mercredi inclusivement: A.M.6.15 à 9.15 \u2014 P.M.12.00 à 18.30 Jeudi et vendredi: A.M.6.15 à 9.15 \u2014 P.M.12.00 à 21.30 Samedi : A.M.9.00 à 12.00 \u2014 P.M.12.00 à 17.30 Le requérant demande à la Commission des transports l'autorisation d'effectuer le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service : Transport d'enfants de trois (3) à sept (7) ans de leur résidence respective située dans St-Bruno - Brossard - Ville Laflèche se rendant à «l'École Maternelle Lussier Enr'g., située au 1682 rue Montarville.St-Bruno, P.Que., et retour.» Egalement demande est faite pour le transport de ces mêmes enfants de « l'Ecole St.Antoine route: Service every thirty minutes.Terminal: departure via Parent - Ste.Anne - Du Palais on the left - Labelle on the left - De Martigny on the left - entrance at Zeller's, 9th Street \u2014 20th on the right -St.Antoine Boulevard on the left - 24th on the right - 22nd on the right - 19th on the right - St.Antoine Boulevard on the left -Highway 11 - on the right St.Georges Street - Parent on the right - and thence to the terminal.Ste.Paule route: Service every thirty minutes.Terminal: departure via Parent - Ste.Anne-Du Palais on the left - St.Georges on the right - bypass 100th Street - entrance at Lafontaine Centre - 106th on the left -Highway 11 - Shopping centre on the left -St.Jérôme entrance - Labelle Street - Parent on the left - and thence to the terminal.Laviolette and Ste.Marcelle routes: An hourly ser\\ ice.Terminal: departure via Parent - Ste.Anne - Du Palais on the left - St.Georges on the right - Godmer on the left - De Martigny on the right - Laviolette, Lajeunesse on the left - Raymond on the left - Bastien on the right - Nadon on the right - Bourassa on the right - Mgr.Dubois on the left -Paré on the left - Gauthier on the right -Danis on the left - Brière on the right - turn before Pilon 's - Brière, Castonguay on the right - Labelle on the right - Legault on the left - De Villemure on the left - and thence to the terminal.Domaine route: An hourly service.Terminal: departure via Parent - O'Shea on the right - Latour on the left - 3rd Boulevard on the right - 7th Street - 34th on the left - 10th on the left - 37th on the left -Bian - 3rd Boulevard on the right - Parent on the left - Madeleine on the right - Filion on the left - Trudel - Fournier on the left -Ouimet on the left - Melançon on the right -Parent on the right - Ste.Anne on the left -Legault on the right - De Villemure on the right - and thence to the terminal.Tariffs: Adults: $0.40 per ticket S2.00 per booklet of 6 tickets 5.00 per booklet of 15 tickets Children: .20 per ticket 1.00 per booklet of 6 tickets From Monday to Wednesday inclusive: A.M.6:15 to 9:15 \u2014 P.M.12.00 to 6:30 Thursday and Friday : A.M.6:15 to 9:15 \u2014 P.M.12.00 to 9:30 Saturday : A.M.9:00 to 12:00 \u2014P.M.12.00 to 5:30 The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to provide the following service: Class of permit: Bus service.Service : Transportation of children aged three (3) to seven (7) years from their homes located in St.Bruno - Brossard - City of Laflèche to the following school: l'Ecole Maternelle Lussier Enr'g., located at 1682 Montarville Street, St.Bruno, Que., which they attend, and return.Request is also made for the transportation of these same children from \"l'Ecole Mater- 1924 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9.1971, Vol.106, No.10 Maternelle Lussier Enr'g., à la piscine « Centre Civique St-Hilaire à St-Hilaire, P.Que.et retour durant la période scolaire.» Conditions et restrictions: 1) Ces services ne seront donnés que durant la période scolaire seulement.2) Le détenteur devra maintenir en vigueur, pour la protection des enfants transportés, une assurance de responsabilités légales, conformément aux dispositions de l'Ordonnance générale No 5448 de la Régie des transports, en date du 21 juin 1963.nelle Lussier Enr'g.\" to the pool of Centre Civique St.Hilaire.in St.Hilaire.Que.and return, the foregoing during the school period.Conditions and restrictions: (1) This service shall be operated only during the school period.(2) The permit holder shall maintain a public liability insurance for the protection of the pupils carried, pursuant to the provisions of General Order No.5448, dated June 21, 1963.Rôle M-1192 720-A MTF-1 MAGOG AUTOBUS LTÉE, 401, est, rue Principale.Magog.J1K 1K9 Cté Stanstead, P.Q.La requérante demande à la Commission l'autorisation de majorer ses tarifs de la façon suivante: Taux actuels en vigueur depuis le 5 novembre 1968: Adultes : en espèces SO.25 en billets 2x $0.35 en billets 6x tl.00 Enfants: 5 à 12 ans en espèces $0.15 en billets 2 x $0.25 en billets 10 x $1.00 Demande de majoration de tarifs.Adultes: en espèces en billets 4 x Enfants: 5 à 12 ans en espèces en billets 6 x $0.35 $1.00 $0.25 $1.00 The applicant requests the Commission to authorize it to increase its tariffs as follows: Present rates in force since November 5, 1968: Adults: cash fare $0.25 tickets 2 x $0.35 tickets 6x $1.00 Children: 5 to 12 years old cash fare $0.15 tickets 2 x $0 25 tickets 10 x $1.00 Application for an increase in tariffs.Adults: cash fare $0.35 tickets 4 x $1.00 Children: 5 to 12 years old cash fare $0.25 tickets 6x $1.00 Rôle M-1193 20629-V D-l GILLES DUVAL, 36, rue Dufort, St^Roch-de-l'Achigan.(L'Assomption), Que.Cession de la propriété du système de transport (vente).Du val.Gilles, requérant-vendeur, 36, rue Dufort, St-Roch-de-l'Achigan (l'Assomption), Que.demande l'autorisation de céder à : Duval Transport Enrg., requérant-acquéreur, (Gaston Duval opérant sous le nom de) St-Roch-de-l'Achigan (l'Assomption), Que.Permis No 20629-V Transfer of ownership of transport service (sale).Duval, Gilles, applicant-vendor.36 Dufort Street, St.Roch-de-l'Achigan (l'Assomption), Que.requests authorization to transfer to : Duval Transport Enrg., applicant-purchaser, (Gaston Duval operating under the name of), St.Roch-de-l'Àchigan (l'Assomption), Que.Permit No.20629-V.Rôle M-1194 22586-V D-l GÉRARD DENEAULT, 249, St-Martin, Napierville, Que.Nouvelle demande: La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Transport restreint - service local - contrat- _ Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville, pour la livraison domiciliaire d'huile à chauffage, pour le compte de Cortina Oil Co.Réservoir maximum de 2,200 gallons.New application: The applicant requests authorization from the Commission to provide, under the prescribed conditions, the following transport service : Restricted trucking - local service - contract - ^ Montreal and all points located over a distance of not more than five miles from the limits of said City, for home delivery of heating oil, on behalf of Cortina Oil Co.Maximum tank capacity: 2,200 gal.Rôle M-1195 23464-V D-l 87-V D-3 ROGER TURNER, 566, Verschelden, Ste-Thérèse, P.Q.FINCH A SONS TRANSPORT LTD., 2025, 8t-François Road, Dorval, P.Q.requérant-conjoin t joint applicant.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, le droit de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Classe: Transport restreint - remorquage -Service: Transport par remorquage pour tirer les remorques vides ou remplies du requérant-conjoint; Finch & Sons Transport Ltd.qui agira comme routier; en vertu des clauses du permis 87-V, du roulier.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide, under the prescribed conditions, the following transport service: Class: restricted trucking - haulage -Service : Haulaway transportation to haul the empty or loaded trailers of the joint applicant; Finch & 8ons Transport Ltd.will operate as the carrier; according to the clauses of the carrier's permit 87-V. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 1925 Rôle M-1196 19517-V D-l 5427-V D-5 CLAUDE DAIGNEAULT, 124.De Gaule.Repentigny.P.Q.RIMOUSK1 TRANSPORT LTÉE, 377, 2e Rue Est, Rimouski, P.Q.requérant-conjoint joint applicant.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, le droit de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Classe: Transport restreint - remorquage Service : Transport par remorquage pour tirer les remorques vides ou remplies du requérant-conjoint; Rimouski Transport Ltée qui agira comme roulier: en vertu des clauses a à o inclusivement, du permis permanent du roulier portant le numéro No 5427-V.Rôle M-1197 2290-V D-l RÉJEAN CÔTÉ, La Visitation (Yamaska), Que.Cession de la propriété du système de transport (vente).Réjean Côté demande l'autorisation de céder à: Claude Laplante, requérant-acquéreur Ste-Perpétue (Nicolet).Que., la propriété du système de transport suivant: Permis No 2290-V.o) Transport général - service local - a) La Visitation et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite municipalité.b) Transport général - longue distance -rayon.b) De La Visitation à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites de ladite municipalité en suivant les routes principales et retour.c) Transport général - longue distance -route restreinte - c) De La Visitation, Ste-Monique, La Baie et St-EIphège à Montréal et retour.Rôle M-119S 23087-V D-l BRINK'S SÉCURITÉ COMPAGNIE LIMITÉE, 1000, rue Ottawa.Montréal, Que.Modification (droit additionnel).La partie requérante demande à la Commission d'ajouter à son permis le service suivant: Transport restreint - service local -Québec et tous les points situés sur une distance ne dépassant pas (5) cinq milles des limites de ladite ville, pour le transport de rubans magnétiques, supports de données et autres genres d'enregistrements effectués par ordinateurs, pour le compte des clients utilisant les services d'entreposage offerts par la requérante, dont les entrepôts sont situés au 7 de la rue Vallière, à Québec.Restriction : Le service d'entreposage dont il est fait mention sera donné au moyen de voûtes aménagées pour conserver les pièces ci-haut décrites.Rôle M-1199 19517-V D-3 7737-V D-7 CLAUDE DAIGNEAULT, 124, De Gaule, Repentigny, P.Q., BELLECHASSE TRANSPORT INC., 3.600, boul.Wilfrid Hamel, Québec, P.Q.req u éran t-con j oint joint applicant.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, le droit de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Classe : Transport restreint - remorquage -Service : Transport par remorquage pour tirer les remorques vides ou remplies du requérant-conjoint; Bel léchasse Transport Inc.qui agira comme roulier; en vertu des clauses a à z et aa à ee inclusivement, du permis permanent du roulier portant le numéro 7737-V.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide, under the prescribed conditions, the following transport service: Class: Restricted trucking - haulage -Service: Haulaway transportation to haul the empty or loaded trailers of the joint applicant; Rimouski Transport Ltée will operate as the carrier; according to clauses a to o inclusive of the carrier's permanent permit bearing number 6427-V.Transfer of ownership of transport service (sale).Réjean Côté requests authorization to transfer to: Claude LarMante, applicant purchaser, Ste.Perpétue (Nicolet), Que., the ownership of the following transport service: Permit No.2290-V (a) General trucking - local service - (a) La Visitation and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said municipality.(6) General trucking - long distance - radius - (6) From La Visitation to all points located within a radius of 30 miles from the limits of said municipality along the main Highways and return.(c) General trucking - long distance-restricted route - (c) From La Visitation, Ste.Monique.La Baie and St.Elphège to Montreal and return.Modification (additional right).The applicant requests the Commission to add the following service to its permit: Restricted trucking - local service -Québec and all points located over a distance of not more than (5) five miles from the limits of said City, for the transportation of magnetic tapes, data carriers and other types of computer-produced recordings, on behalf of the customers utilizing the storage services provided by the applicant, whose warehouses are located at 7 Vallière Street, in Québec City.Restriction: The storage service above mentioned will be provided by means of vaults equipped for the conservation of the documents hereinabove described.The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to provide the following transportation service under the prescribed conditions: Class: Restricted trucking - haulage - (haulaway transportation).Service: Haulaway transportation to haul the empty or loaded trailers of the joint applicant, Bellechasse Transport Inc.which will operate as carrier; the foregoing according to clauses a to z and aa to ee inclusive of the carrier's permanent permit bearing number 7737-V. 1926 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 Rôle M-1200 16761-V D-l ROLAND DESAUTELS 0971) ENRG., FERNAND ROCHON, NORMAND ALIX, ALBERT LAFRENIERE, JEAN HOULE, opérant sous le nom de: operating under the name of: 3720 est.Jean-Talon, Montréal 453, Que.Rôle M-1201 23511-V D-3 13963-V D-6 RAYMOND MASSE, 4254, boul.Henri-Bourassa, Montréal-Nord, P.Québec.SPEEDWAY EXPRESS LTD., 20, boul.Marie-Victorin, Boucherville, P.Québec, requérant-conjoint joint applicant.Rôle M-1202 23511-V D-2 7737-V D-6 RAYMOND MASSE, 4254, boul.Henri-Bourassa, Montréal-Nord, P.Québec.BELLECHASSE TRANSPORT INC., 20, boul.Marie-Victorin, Boucherville, P.Québec, requérant-conjoint joint applicant.Rôle M-1203 22092-V D-l 6793-V D-13 GILLES LAMBERT.55, Dunn, Victoriaville.P.Q.BRAZEAU TRANSPORT INC., 380.Burke.Rouyn, Cté Témiscamingue, P.Québec, requérant-conjoint joint applicant.Rôle M-1204 4608-V D-2 PAPINEAU TRANSPORT INC., B.P.100.St-Jérôme, Que.J7Z 5T7.Modification de permis (droit additionnel).La partie requérante demande à la Commission d'ajouter à son permis le service suivant : Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - De Montréal à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites de ladite cité, pour le transport de papeterie, et retour, avec marchandises refusées, pour le compte de la Cie J.B.Roland & Fils.Modification of permit (additional right).The applicant requests the Commission to add to its permit the following service: Restricted trucking - long distance - radius-contract- From Montreal to all points located within a radius of 30 miles frc*m the limits of said City, for the transportation of stationery, and return with refused goods, on behalf of Cie J.B.Roland & Fils.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, le droit de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Classe : Transport restreint - remorquage -Service : Transport par remorquage pour tirer les remorques vides ou remplies du requérant-conjoint; Speedway Express Ltd.qui agira comme roulier; en vertu de la clause a, du permis permanent du roulier portant le numéro No 13903-V D-C.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, le droit de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Classe : Transport restreint - remorquage -Service : Transport par remorquage pour tirer les remorques vides ou remplies du requérant-conjoint; Bellechasse Transport Inc.qui agira comme roulier; en vertu des clauses a à 2 et aa à dd inclusivement du permis permanent du roulier portant le numéro 7737-V D-6.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, le droit de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Classe: Transport restreint - remorquage -Service : Transport par remorquage pour tirer les remorques vides ou remplies du requérant-conjoint; Brazeau Transport Inc.qui agira comme roulier; en vertu des clauses c à z, aahzz inclusivement aaa h/ff ainsi que toutes les clauses du permis temporaire expérimental du 14/02/73.Modification de clause: La partie requérante dont la clause c se lit comme suit: Transport général-longue distance-route restreinte - De St-Jérôme, St-Antoine-des-Laurenti-des, St-Janvier, Blainville, Ste-Thérèse, Ste-Thérèse-Ouest, Rosemère, Bois des Filion à Montréal, et retour.Rest riction : La détentrice n'est pas autorisée à desservir les localités situées dans le rayon de 5 milles des points mentionnés, sauf St-Jérôme et le Montréal-Métropolitain.Demande que la restriction apparaissant à Cette clause soit enlevée de façon à lui permettre de desservir tous les endroits situés dans le rayon de 5 milles des points nommés à ladite clause.The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to provide the following transportation service, under the prescribed conditions: Class: Restricted trucking - haulaway transportation.Service: Haulaway transportation to haul the empty or loaded trailers of the joint applicant, Speedway Express Ltd.which will operate as carrier; the foregoing according to clause a of the carrier's permanent permit bearing number 13963-V D 6.The applicant requests the Quebec Transport Commission to authorize it to provide the following transportation service, under the prescribed conditions: Class: Restricted trucking - haulaway transportation.Service: Haulaway transportation to haul the empty or loaded trailers of the joint applicant, Bellechasse Transport Inc., which will operate as the carrier; the foregoing according to clauses a to z and aa to dd inclusive of the carrier's permanent permit bearing number 7737-V D-6.The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to provide the following transportation service, under the prescribed conditions: Class: Restricted trucking - haulaway transportation -Service: Haulaway transportation to haul the empty or loaded trailers of the joint applicant, Brazeau Transport Inc., which will operate as the carrier; the foregoing according to clauses c to z, aa to zz inclusive, and aaa to /// and according to all clauses of the experimental temporary permit issued on 14/02/73.Modification of clause: The applicant whose clause c reads as follows: General trucking - long distance - restricted route - From St.Jérôme, St.Antoine-des-Lauren-tides, St.Janvier.Blainville.Ste.Thérèse, Ste.Thérèse-West, Rosemère, Bois-des-Filion to Montreal, and return.Restriction : The holder is not authorized to serve the localities situated within a radius of 5 miles from the points mentioned, except for St.Jérôme and Greater Montreal.The applicant requests that the restriction appearing in this clause be removed in order that it may be authorized to serve all points located within the radius of 5 miles from the places named in said clause. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106< année, n° 10 1927 Rôle M-1205 11009-V D-l MORGAN STORAGE & MOVING LTD., 560, Orly Avenue, Dorval, Pointe Claire 760, P.Que.mise en cause.Cession de la propriété de transport (vente d'actions).La compagnie Canada Steamship Lines Ltée, qui possède toutes les actions émises par la compagnie mise en cause, a fait une demande à la commission en vue de faire approuver le transfert de toutes lesdites actions en circulation à Johnston Terminals & Storage Ltd., 2020, rue Yukon, Vancouver (C.-B).Cette demande est faite conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi des transports du Québec.Distribution actuelle: Canada Steamship Lines Ltd.20,000 actions Eric F.Stephan, Prés.1 action Distribution future: Johnston Terminais & Storage Ltd.19,999 actions Eric F.Stephan 1 action James N.Nethven 1 action Transfer of ownership of a transportation service (sale of shares).Canada Steamship Lines.Limited, which owns all shares issued by the company mise en cause, has filed an application with the Commission for the approval of the transfer of all of the said outstanding shares to Johnston Terminals & Storage Ltd., 2020 Yukon Street, Vancouver, B.C.Such application is made in accordance with the terms of article 39 of the Transportation Act of Québec.Present distribution: Canada Steamship Lines Ltd.20,000 shares Eric F.Stephan, Pres.1 share Future distribution: Johnston Terminals & Storage Ltd.19,999 shares Eric F.Stephan 1 share James N.Nethven 1 share Rôle M-1206 1769-A D-l JEAN-LUC ROBERT, 116 rue Seigneuriale Oueet, St-Bruno, Cté Verchères, P.Q.La requérante demande à la Commission des transports l'autorisation d'effectuer le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: Transport d'enfants de 3 à 7 ans de leur résidence située dans la Ville de St-Bruno et fréquentant l'Ecole maternelle suivante, et retour.« Pensionat des Sacrés-Coeurs », 1575, Rang des Vingt, St-Bruno, de Montarville, P.Q.et ce pour la période scolaire.Territoire: Ce service sera donné dans les limites de St-Bruno seulement.The applicant requests from the Transport Commission the authorization to.provide the following service: Class of pprmit: Bus service.Service: Transportation of children aged 3 to 7 year from their residences located in the Village of St.Bruno, to the following kindergarten which they attend, and return: \"Pensionnat des Sacré-Coeurs\", 1575, Rang des Vingt, St.Bruno-de-Montarville, P.Q.during the school year.Territory: This service shall be given within the limits of St.Bruno only.Rôle M-1207 23566-V D-l S & R TRANSPORT, (Samuel Joseph Grischkan, opérant sous le nom de operating in the name of:) 44, rue Whiteoak, Sollard-ôes-Ormeaux, P.Que.La partie requérante s'adresse à la Commission des transports du Québec dans le but d'obtenir le service de transport suivant: Classe: Transport restreint - longue distance - contrat-Service: De Montréal à tous les endroits situés dans un rayon de 10 milles des limites de ladite ville; pour le transport de marchandises pour le compte d'Atlas Sponging Inc.(Montréal) et retour avec des marchandises endommagées ou refusées.The applicant requests from the Québec Transport Commission the following transport service: Class: Restricted trucking - long distance -contract.Service: From Montreal to points situated within a radius of 10 miles of the limits of the said city; for the transportation of merchandise for the account \"Atlas Sponging Inc.\" (Montreal) and return with damaged or rejected merchandise.Rôle M-1208 21252-V D-l ALL CITY MOVING & STORAGE LIMITED, 37 Bulwer Avenue, Toronto, Ontario.Transfert à: D.CURRIER MOVING & CARTAGE CO.LTD., 167 Lindy Lou Road, Weston, Ontario.Au Québec: G.O.Q.No 46.1973 20 Longtin, St-Constant, P.Que.Le requérant vendeur s'adresse à la Commission des transports du Québec dans le but d'obtenir le droit de vendre, aux conditions réglementaires, son permis portant le No 21252-V, au requérant-acquéreur: D.Currier Moving & Cartage Co.Ltd.Ledit permis 21252-V du requérant-vendeur se lit comme suit: Classe: Service restreint - longue distance - irrégulier: Service: De la frontière Québec-Ontario (tous ports d'entrée) à toutes les localités situées dans la province de Québec et retour, pour le transport d'articles ménagers, selon l'article 51 de l'Ordonnance générale sur le transport, avec des véhicules spécialement aménagés pour le transport de ces marchandises.The applicant vendor requests from the Québec Transport Commission the right to sell its permit numbered No.21252-V, to the applicant purchaser: D.Currier Moving & Cartage Co.Ltd.under the prescribed terms and conditions.The said permit 21252-V held by the applicant vendor shall read as follows in the future: Class: Restricted service - long distance - irregular: Service: From the Québec-Ontario border (all ports of entry) to all localities situated in the Province of Québec, and return, for the transportation of household goods as defined by article 51 of General Order on Trucking, with vehicles specially equipped for the transportation of such goods. 1928 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol 106, No.10 Restriction : Ce service doit être exploité avec le certificat complémentaire No X-1236.émis par la Ontario Highway Transport Board, en date du 12 décembre 19fi8.et soua réserve de la restriction s'y rattachant.Si le transfert susmentionné est approuvé par la Commission des transports du Québec, la restriction se rattachant audit permis devra, à l'avenir, se lire comme suit: Restriction : Ce service doit être exploité avec le certificat complémentaire No X-1236, délivré par la Ontario Highway Transport Board, en date du 9 octobre 1973, et qui approuve le transfert à D.Currier Moving & Cartage Co.Ltd.Rôle M-1209 23497-V D-3 7737-V D-5 RONALD DESCHENEAUX.7754 rue Lecourt, Montréal, Qu£.Tireur.BELLECHASSE TRANSPORT INC., 3600 boul.Hamel, Les Saules, Québec 8.Que.Tiré.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, le droit de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Classe: Transport restreint - remorquage - Service: Transport par remorquage pour tirer les remorques vides ou remplies du requérant-conjoint; Bel le chasse Transport Inc.qui agira comme roulier; en vertu des clauses a à r et aa à dd inclusivement, du permis permanent du roulier portant, le numéro 7737-V.Rôle M-1210 23653-V D-l LEBEAU, YVES, Rang Grand Bois, Mont St-Grégoire, Cté d'Iberville, P.Q.La partie requérante demande à la Commission l'autorisation de donner aux conditions réglementaires, le service suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - vannes sanitaires - De la ville et de la paroisse d'Iberville, la paroisse Ste-Anne de Sabrevois, Mont St-Grégoire paroisse et village, St-Alexandre paroisse et village, au dépotoir de Mont St-Grégoire, pour le transport d'ordures ménagères, rebuts et déchets industriels, avec des vannes sanitaires.Rôle M-12I1 22652-V D-I CHAPUT TRANSPORT ENRG., 'Claude Charbonneau.opérant sous le nom de: operating under the name of:) B.P.7.St-Pie de Bagot.Que.Cession de la propriété du système de transport (vente).Claude Charbonneau demande l'autorisation de céder à: Chaput Transport Enrg., requérant-acquéreur, (Marcel Goyette opérant sous le nom de), 20, rue Ste-CéoUe, St-Pie de Bagot, Que.la propriété du système de transport suivant: Permis No 22652-V.Transport général-longue distance-route restreinte - De St-Pie de Bagot à Chambly canton et Montréal, et retour.Restriction : This service is to be operated in conjunction with a complementary certificate No.X-1236 issued by the Ontario Highway Transport Board, dated December 12, 1968 and subject to the restriction attached thereto.If the above-mentioned transfer is approved by the Québec Transport Commission, the restriction attaching to said permit shall read as follows in the future: Restriction : This service is to be operated in conjunction with a complementary certificate No.X-1236.issued by the Ontario Highway Transport Board, dated October the 9th, 1973; approving the transfer to D.Currier Moving & Cartage Co.Ltd.The applicant requests from the Québec Transport Commission, the right to provide the following transportation service under the prescribed terms and conditions: Class: Restricted trucking - haulaway transportation service: Service: Haulaway transportation service to haul the trailers (empty or loaded) belonging to the joint-applicant Bellechasse Transport Inc.which will act as carrier; the foregoing according to clauses a to 2 and aa to da inclusive of the carrier's permanent permit bearing number 7737-V.The applicant requests from the Commission the authorization to provide the following transportation sen-ice under the prescribed terms and conditions: Restricted trucking - long distance - restricted route - sanitary vans - From the Town and the Parish of Iberville, the Parish of Ste.Anne-de-Sabrevois, Mont St.Grégoire Parish and Village.St.Alexandre Parish and Village, to the dump of Mont St.Grégoire, for the transportation of garbage, trash and industrial wastes, with sanitary vans.Transfer of ownership of a transport service (sale): Claude Charbonneau requests authorization to transfer to : Chaput Transport Enrg., applicant-purchaser, (Marcel Goyette operating under the name of:) 20 Ste.Cécile Street, St.Pie-de-Bagot.Que.the ownership of the following transport service : Permit number 22652-V.General transport - long distance - restricted route - From St.Pie-de-Bagot to Chambly Township and Montreal, and return.56274-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1971,, 106' année, n° 10 1929 I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu » : La Commission donne avis qu'elle entend décider de l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire étrt entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.Rôle Q-0839 23620-V-P-l MAURICE FILTEAU, 1626, Chemin Sullivan, Val d'Or.(Abitibi).Aux fins de reviser la décision QS-180, relativement au cautionnement de l'opposante.Rôle Q-0840 4535-V-P-l JOSEPH FILLION, 214 rue Principale, Lyster (Mégantic).Aux fins de révoquer la clause a du permis de Joseph Filion, tel que prévu dans le considérant de la décision du 16 janvier 1974 (QCR-407).V \u2014Avis de décisions rendues : La Commission donne avis de la nature des décisions suivantes, prises par elle, conformément aux dispositions Je l'article 2.58 du Règlement No 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément à l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.I \u2014 Notice \" proprio motu \" by the Commission : The Commission gives notice of its intention to render a decision in the following matters in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publication.With the purpose of revising decision QS-180, with regard to the opponent's deposit.For the purpose of revoking clause a of the permit held by Joseph Filion, as provided in the preamble of the decision dated January 16, 1974 (QCR-407).56274-0 V \u2014 Notice of decisions rendered : The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it, in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation No.2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicant*\t\t\t\tCase\t MCR-721\t20-02-74\t19665-V\t\t\t\t\t \t\tPIERRE TRANSPORT\t1-19-39\t4411\t28-07-73\tM-4391\tAccordée, fait revivre en \t\tLTEE\t\t\t\t\tpartie le permis de Pierre Transport Ltée Granted partly revives the permit held by \t\t\t\t\t\t\tPierre Transport Ltée.MCR-722\t20-02-74\t19665-V\t\t\t\t\t \t\tPIERRE TRANSPORT\t3-19-6\t1782\t24-04-73\tM-3912\tAccordée / Granted \t\tLTEE\t\t\t\t\t \t\tRequérante-venderesse\t\t\t\t\t \t\tA pplicant-vendor\t\t\t\t\t \t\t1234-V\t\t\t\t\t \t\tBEL-MAR EXPRESS\t\t\t\t\t \t\tENRG.\t\t\t\t\t \t\tRequérant-acquéreur\t\t\t\t\t \t\tA pplicant-purchaser\t\t\t\t\t MCR-727\t20-02-74\t23313-V\t\t\t\t\t \t\tLUCIEN POIRIER\t1-15-3\t3969\t07-07-73\tM-4475\tAccordée / Granted MCR-731\t20-02-74\t331-V\t\t\t\t\t \t\tMcCRUM TRANSPORT\t1-14-95\t3886\t30-06-73\tM-4415\tRejetée / Rejected \t\tLTD.\t\t\t\t\t 1030 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9.7974.VéL 106, No.10 No MCR-714 MCR-725 ML-219 MPV-201 MPV-202 MPV-204 MPV-205 TF Date 18-02-74 20-02-74 18-02-74 20-02-74 20-02-74 20-02-74 20-02-74 Requérants Applicants 18215-V-P-l CONTINENTAL EXPRESS LINES LTD Avis rie la Commission « Proprio Motu c Notice \"proprio motu\" by the Commission 2483-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS'N.Avis de la Commission ¦ Proprio Motu » Notice \"proprio motu\" by the Commission 8336-V-P-l JACQUES CROTEAU Avis de la Commission « Proprio Motu » Notice \"proprio motu\" by the Commission 2645-A-D-2 PAQUETTE AUTOBUS INC.602-A-D-5 SERVICE DE LIMOUSINE MURRAY HILL LTEE MURRAY HILL LIMOUSINE SERVICE LTD.2594-A-D-2 METROPOLITAIN SUD (1967) INC.2096-A-S-4 METROPOLITAIN PROVINCIAL (1967) INC.Bulletin G.O.Q.page date 7249 7660 6808 327 '.19 08-12-73 12-02-74 Cause Case M-761 M-767 29-12-73 17-11-73 19-01-74 12-01-74 M-769 M-574 M-898 M-773 Décisions La Commission annule le pei mis de Continental Express Lines Ltd./ The Commission cancels the permit held by Continental Express Ltd.La Commission ajoute la modification de tarif omise dans la publication de la requête du Râle M-580 et dans la décision MCR-689 du 5-C2-74.The Commission adds the modification of tariff omitted in the publication of the application of Roll M-iSO and in decision MCR-689 dated 6-08-74.La Commission corrige la décision ML-83 du 29-08-73 relativement à la date de l'expiration et les taux du contrat de location./ The Commission corrects decision MLS S dated 19-08-73 relatively to the date of expiry of the lease and to the rates applicable thereto.Accordée / Granted Accordée ' Granted Accordée / Granted Demande de modification à certains tarifs de transport de personnes par autobus (article 2.71 - règlement No 2).La requérante, en vertu d'une situation d'urgence, demande à la Commission des transports une autorisation spéciale de majorer de 9.1% les tarifs de ses services réguliers vers les banlieues ouest, sud-ouest et est, pour rcncontier des frais substantiels encourus récemment.MCR-723 TF MCR-724 MCR-720 20-02-74 20-02-74 20-02-74 11165-V MICHAEL'S CARTAGE LTD.234I9-V-D-) C.L.LIVRAISON ENRG.22836-V-D-l JEAN-GUY PARENT Accordée / Granted Application for modification of certain tariffs for the transportation, by bus, of passengers (section 2.71 - regulation No.2).The applicant, owing to a state of emergency, requests from the Transport Commission a special authorization to increase by 9.1% the tariffs of its regular routes serving the western, southwestern and eastern suburbs, to cover substantial costs recently incurred.7258 6810 7122 18-12-73 17-11-73 01-12-73 M-716 M-583 M-684 Accordée / Granted Accordée,' Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 1931 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t No\t\tRequérants\t\t\t\tCause\t \tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\t\tCase\t MCR-728\t20-02-74\t1417-V-D-l TF\t\t\t\t\t TF\t\tTRANS-ILE INC.\t\t7123\t01-12 73\tM-689\tAccordée /Granted MCR-729\t20-02-74\tCANADIAN TRANS-\t\t7123\t01-12-73\tM-690\tAccordée / Granted TF\t\tPORT TARIFF BUREAU ASS'N.\t\t\t\t\t MCR-730\t20-02-74\tNIAGARA FRONTIER\t\t105\t12-01-74\tM-798\tAccordée.' Granted TF\t\tTARIFF BUREAU INC.\t\t\t\t\t MCR-715\t21-02-74\tBT-2 M-D-l TF\t\t\t\t\t TF\t\tCANADIAN TRANS-\t\t7422\t15-12-73\tM-795\tAccordée / Granted \t\tPORT TARIFF\t\t104\t12-02-74\tM-795\t \t\tBUREAU ASS'N.\t\t\t\t\t MCR-558\t07-12-73\t15723-V\t\t\t\t\t \t\tCOTTRELL\t\t3229\t26-05-73\tM-4395\tAccordée / Granted \t\tFORWARDING CO.\t\t\t\t\t \t\tLTD.\t\t\t\t\t \t\tModification de permis Vol.\t\t\t\t\t \t\t1.No 10, requête 61\t\t\t\t\t \t\tModification of permit Vol.1, No.10, Application 61\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t MCS-341\t15-02-74\t1930-V-D-3 TF\t\t\t\t\t TF\t\tPROVOST CARTAGE\t\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tINC.\t\t\t\t\t La requérante a fait une demande suivant l'article 2.70.1 du règlement No 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports, a la Commission et a proposé une modification de certains de ces tarifs comme suit: Annulation du tarif de taux No 39.remplacement par le tarif No 39-A couvrant le transport de produits pétroliers entre les points des provinces de Québec, Nouveau-Brunswick et l'Ontario, ce tarif ayant été soumis pour approbation avec la requête.The applicant has submitted a request to the Commission, pursuant to section 2.70.1 of Regulation 2 on the rules of practice and rates for internal management of the Transport Commission, and has proposed a modification of some of its tariffs as follows: Cancellation of the rate tariff No.39, to be replaced by tariff No.39-A covering the transportation of oil products between points in the Province of Québec, New Brunswick and Ontario submitted for approval with the application.MCS-342 MCS-345 TF MCS-346 TF MCS-343 MCS-344 MCR-716 MCR-717 TF MCR-718 TF 18-02-74 20-02-74 20-02-74 18-02-74 18-02-74 18-02-74 18-02-74 18-02-74 23120-V-D-l RODERICK BOURQUE 1930-V PROVOST CARTAGE INC.1930-V-D-4 TF PROVOST CARTAGE INC.17359-V-RC 1045-C « Q » ROBERT DESHAIES 22211-V CLAUDE BELLEMARE 22478-V-D-l ANDRE J.BERGERON Requérant-vendeur A pplicant-vendor 21339-V DEL TRANSPORT LTEE Requérante-acquéreur A pplicant-purchaser 22779-V-D-l TF KWIKASAIR LTD.BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.1-11-42 1-10-69 6418 7260 6235 99 3363 3231 6418 6233 6235 03-11-73 08-12-73 27-10-73 12-01-74 02-06-73 26-05-73 03-11-73 27-10-73 27-10-73 M-412 M-724 M-335 M -771', M-4402 M-4468 M-411 M-321 M-336 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Désistement / Withdrawal Désistement, le requérant est exempté du délai de six (6) mois pour présenter une requête.Withdrawal, the applicant is exempted from the six (6) month time limit to submit an application.Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 1932 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 9.1971, Vol.106, No.10 No\tDate\tRequérants Applicants\tBulletin\t( page\t3.O.Q.date\tCause Case\tDécisions MCR-719 TF MCR-720 TF\t18-02-74 20-02-74\t5595-TFM 373-V BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.pour CHALUT TRANSPORT INC.21136-V-D-l TF GREAT WEST TRANSPORT CO.\t\t6233\t27-10-73\tM-320\tAccordée / Granted Accordée / Granted Demande à la Commission des transports du Québec une fixation de taux compétitifs au chemin de fer pour le transport de fromage de Montréal a Winnipeg au tarif suivant: $2.27 -45,000 lbs.conformément à l'article 2.64.section 3 du règlement No 2 concernant la concurrence tarifaire avec transport feiroviaire.En vertu, de l'article 2.64 du règlement 2 sur les règles de pratique et de tégie interne de la Commission.MCS-347 MCS-348 M L-216 ML-217 ML-223 ML-220 ML-221 TF 20-02-74 21-02-74 OS-02-74 11-02-74 20-02-74 18-02-74 18-02-74 23121-V-D-l FLOYD RUSSEL 23438-V-D-l DOUGLAS CHARLES GURNEY Voiturier-remorqueur Haulaway operator 87-V-D-l FINCH A SONS TRANSPORT LIMITED Voiturier-roulier / Carrier 919-DYV METRO TANK LEASING (MONTREAL! INC.947-DYV SOULIERES SERVICE DE LOCATION RENTAL (François Soulières) 934-DYV CENTRE DE LOCATION PYRAMIDE INC.PYRAMIDE RENT-ALL CENTRE INC.767-DY LES ENTREPRISES B.C.ENRG.8-DYV-D-l LAUZON DRIVE YOURSELF INC.Requests from the Québec Transport i.ommissio.a nxauon of rates to complote with those of rai road carriers for the transportation of cheese from Montreal to Winnipeg at the following tariff: $2.27 - 45,0001ba.in conformity with section 2.64, part 3 of Regulation No.2 respecting laritl competition with railroad carriers.Pursuant to section 2.64 of Regulation 2 on the rates of practice and rates for internal management of the Commission.1-8-166 1-16-51 3-19-69 1-9-44 6418 6424 6-128 2461 4132 2072 3027 6277 03-11-73 03-11-73 03-11-73 21-04-73 21-07-73 07-04-73 19-05-73 08-09-73 M 113 M-421' M-440 M-4244 M-4494 M-4008 M-4338 M-161 Désistement / Withdrawal Accordée / Granted Accordée / Granted Désistement, demande rejetée / Withdrawal, application rejected.Désistement / Withdrawal Rejetée / Rejected Désistement / Withdrawal Accordée / Granted PERMIS SPÉCIAUX / SPECIAL PERMITS No du répertoire chronologique\tNom du requérant\tValidité: de:.à:\tDétails du permis Chronological Repertory No.\tName of Applicant\tValidity Period\tParticulars of permit MS-146 4245-V-8-1\tSANGUINET EXPRESS CO.LTD.\t9 février 1974 February 9.1974\tPermis spécial - Autorisation de louer à court terme des véhicules motorisés / Special permit -Authorisation to lease motorized vehicles on a short-term basis. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, ?i° 10 1933 No du répertoire chronologique Chronolooical Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Détails du permis Particulars of permit MS-448 23347-V-S-l MS-449 23570-V-S-l CHATEAUGUAY & MOVING REG'D LANDRY TRANSPORT ENRG.MS-450 22273-V-S-2 REAL LAVOIE MS-45I 11907-V-S-l MS-452 8592-V-S-l MS-463 3566-A-S-l MS-454 2020-A-S-2 PELLETIER TRANSPORT LTEE LUDOVIC MONTPETIT INC.LES AUTOBUS ROLAND INC.TRANSPORT CHARTRAND INC.Demande de permis spécial rejetée - Château-guay et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas a) 5 milles b) 30 milles, et retour / Application for a special permit rejected - Châteauçuay and ail points located over a distance of not more than (a) S miles (b) 30 miles, and return.Demande de permis spécial rejetée - Montréal-Métropolitain pour le transport de commandes d'épicerie et marchandises nécessaires à l'approvisionnement de: Four Brothers Food Importers Co.Ltd., et de Bros Supermarket Co.Ltd.Application for a special permit rejected \u2014 Greater Montreal for the transportation of grocery orders and goods required for supplying: Four Brothers Food Importers Co.Ltd., and Bros.Supermarket Co.Ltd.Demande de permis spécial rejetée - De Water-ville, Québec à la frontière Québec-Etats-Unis (tous ports de sortie) De Ste-Aurélie à la frontière Québec-Etats-Unis (tous ports de sortie) pour le transport de bois préparé, destiné aux états suivants: Vermont, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvanie.Delaware, Maryland, Virginia, Rhode Island et Washington, D.C., pour le compte de Fur-man Lumber Inc./ Application for a special permit rejected - From Watcrville, Québec, to the Québec-Ûnited States border (all ports of exit) From Ste.Aurélie to the Québec-United States border (ail ports of exit) for the transportation of dressed lumber, shipped to the following States: Vermont, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Rhode Island and Washington D.C., on behalf of Fur-man Lumber Inc.Demande de permis spécial rejetée - De Rawdon et Ste-Julienne à Montréal, et retour / Application for a special permit rejected - From Rawdon and Ste.Julienne to Montreal, and return.Demande de permis spécial rejetée - De Beau-harnois à Melocheville à tous les endroits situés dans un rayon de 200 milles pour le transport de matériel en vrac par camion à bascule, pour le compte de Union Carbide Canada Ltd.(Metal & Carbon Division) / Application for a special permit rejected - From Beauharnois to Melocheville to all pointt located within a radius of 200 miles for the transportation of materials in bulk, by dump truck, on behalf of Union Carbide Canada Ltd.(Metal & Carbon Division).Demande de permis spécial rejetée - Service urbain dans la Cité de St-Jérôme et les villes de St-Antoine et Lafontaine suivant parcours, horaires et tarifs décrits à la requête / Application for a special permit rejected - Urban service in the City of St.Jérôme and the Towns of St.Antoine and Lafontaine according to routes, timetables and tariffs described in the application.Demande de permis spécial rejetée - Transport des employés de United Aircraft, du Boul.Marie-Victorin à Longueuil.à l'intersection des rues Dauvergne et d'Anjou, Longueuil, et retour / Application for a special permit rejected-Transportation of the employees of United Aircraft, from Marie-Victorin Boulevard to Longueuil, at the intersection of Dauvergne and d'Anjou Streets, Longueuil, and return. 1934 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, -Vo.10 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.MS-456 23465-V-S-l MS-462 1256-V-S-l MS-4S.1 218B-A-S-1 MS-464 16639-V-S-2 Nom du requérant Name of Applicant MONETTE M.LIONEL A.& F.BAILLARGEON EXPRESS INC.MME HUGUETTE LKBOEUF LES ENTREPRISES M.H.T.LIMITEE MS-465 10043-V-S-l MS-467 M-505409 S-l OVERNITE EXPRESS LTD.JOHN DONNELLY MS-468 JOHN DONNELLY M-S05408 S-l MS-469 1287-DY 1069-DYV-S-l MS-470 13530-V-S-l MS-466 77-V-S-l BELLEMARE DATSUN LIMITEE G.D.SPARKS LIMITED LAFRAMBOISE TRANSPORT ENR'G Validité: de:.à Validity Period 29/01/75 Décision finale de la Commission Final decision of the Commission.Décision finale de la Commission Final decision of the Commission.Période scolaire I973/74 1973/74 school year.29/01/74 Decision finale de la Commission Final decision of the Commission.Détails du permis Particulars of permit 27/01/74 10/02/74 Décision finale de la Commission Final decision of the Commission.Décision finale de la Commission Final decision of the Commission.Permis spécial - Autorisation à Monette M.Lionel, de tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Bellechasse Transport Inc / Special permit - Authorization granted to Afonette M.Lionel to haul, with his duly-registered tractors, the trailers of Bellechasse Transport Permi«« spécial - En donnant le service autorisé par les clauses a-1 et a-4 de son permis No 1256-V, la détentrice est autorisée à tirer les remorques arrivant à/ou partant de Montréal par service régulier de « piggy back » pour le compte de CP.Rail /Special permit-When providing the service authorized by clauses a-1 and a-4 of its permit No.1256-V, the holder is authorized to haid the trailers arriiing at/or leaving Montreal by \"piggy back\" regular service on behalf of CP.Rail.Permis spécial - Transport d'enfants de 3 à 7 ans de leur résidence respective et fréquentant l'école maternelle, et retour / Special permit-Transportation of children aged S to 7 years, from their homes to the kindergarten, and return.Permis spécial - Transport de maisons (système fold-a-way) et ses composants de tout point à tout autre point dans la province de Québec, pour le compte de Atco Québec Ltd./ Special permit - Transportation of houses (fold-a-way system) and components thereof, from any point to any other point in the Province of Québec, on behalf of Atco Québec Ltd.Permis spécial - Transport de Motoneiges pour lecomptedu* ClubEclairlnc.»danslescadres des festivités du club / Special permit - Transportation of snowmobiles on behalf of \"Club Eclair Inc.\" in connection with the club's activities.Demande de permis spécial rejetée - Autorisation de transporter des matériaux en vrac, selon le règlement numéro 12, dans la région numéro 10.Application for a special permit rejected-Authorization to transport bulk materials as her regulation 12, in region No.10.Demande de permis spécial rejetée - Autorisation de transporter des matériaux en vrac, selon le règlement numéro 12, dans la région numéro 10.Application for a special permit rejected \u2014 Authorization to transport bulk materials as her regulation 12.in region No.10.Permis spécial - Location à court terme (moins d'un an) de véhicules de marque Datsun à 10,305 Papineau, Montréal / Special permit-Leasing on a short-term basis (less than one year) of Datsun vehicles at 10,305 Papineau, Montreal.Permis spécial - Transport par camions-citernes, de lait et ses sous-produits, des frontières Québec-Ontario (tous ports d'entrée), à destination de Montréal pour le compte de Cow et Gate (Canada) Limited et leurs établissements.Special permit - Transportation, by tank trucks, of milk and its by-products, from the Québec-Ontario borders (all ports of entry), shipped to Montreal on behalf of Cow and Gate (Canada) Limited and their premises.Demande de permis spécial rejetée - De St-Jé-An%n ,es endr?»ts situés dans un rayon de 200 milles de cette localité, pour le transport de margarine, par camions isothermes, pour le compte de Agra Foods Ltd./ Application for a GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 1935 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.MS-473 23321-V-S-3 MS-471 11767-V-S-2 MS-472 18010-V-S-l Nom du requérant Name of Applicant GEORGE A.LEWIS LTD.PLAISANCE TRANSPORT INC.BEAUCHAMP EXPRESS (YOLANDE BEAUCHAMPS) Validité: de:.à: Validity Period 6 mois / 6montha Décision finale de la Commission Final decision of the Commission.Détails du permis Particulars of permit special permit rejected - From St.Jérôme to all points located within a radius of 200 miles from said locality, for the transportation of margarine, by temperature-controlled vehicles, on behalf of Agra Foods Ltd.Demande de permis spécial rejetée - Voyager sur les routes du Québec pour se rendre à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick, tout en continuant d'avoir le droit d'utiliser le port d'entrée de Blackpool pour voyager aux Etats-Unis, à destination du port d'entrée de St-Stephen, tel qu'actuellement autorisé pour le transport d'expéditions originant de St^Jean^Baptiste-de-Rouville, Ste-Rosalie, Berthier, pour les produits de volaille originant des installations de Québec Poultry Ltée situées à ces endroits; de Montréal-Métropolitain pour les produits de viande originant des installations ou endroits de cueillette de Canada Packers Limited.Provi-sioners Maritimes Limited, Blue Buoy Foods Limited, Swift Canadian Co.Ltd.(Napier-ville): et pour les fruits et légumes originant des entrepôts de Québec Vegetables Distributors Inc.f Application for a special permit rejected - To travel on the highways of the Province of Québec to reach the Québec-New Brunswick border, while retaining authorization to utilize the port of entry of Blackpool in order to travel in the United States, the point of destination being: the port of entry of St.Stephen, as presently authorized for the transportation of shipments originating from St.Jean-Baptiste-de-RouviUe, Ste.Rosalie, Berthier, for poultry products originating from the Québec Poultry Ltée plants located at the aforementioned points: from Greater Montreal, for meat products originating from the plants or pick-up points of Canada Packers Limited, Provisioners Maritimes Limited, Blue Buoy Food Limited, Swift Canadian Co.Ltd.(Napierville); and for fruits and vegetables originating from the warehouses of Québec Vegetables Distributors Inc.Demande de permis spécial rejetée - De Prince-ville à la frontière Québec-Ontario, pour le transport de bois préparé; pour le compte de o Les Entreprises P.Bonhomme Ltée » / Application for a special permit rejected - From Prince-ville to the Québec-Ontario border, for the transportation of dressed lumber; on behalf of \"Les Entreprises P.Bonhomme Ltée\".Permis spécial - Montréal et tous les endroits situés sur une distance n'excédant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport de rouleaux de papier; pour le compte de Ronalds Federated Ltd., Montréal Offset, Montreal Standard et Schenker of Canada Ltd./ Special permit \u2014 Montreal and ail points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said City, for the transportation of rolls of paper; on behalf of Ronalds Federated Ltd., Montreal Offset, Montreal Standard and Schenker of Canada Ltd.56274-0 1030 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol 106, No.10 Places d'affaires dans la Province Places of Business in the Province CANADA TRANSPORT LIMITED Avis est donne que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « CANADA TRANSPORT LIMITED » est 11242 Est, boul.Gouin, Rivière-des-Prairies, Montréal.Les procureurs de la compagnie.Paquette, Paquette, 56280-o Perreault & Rivet.CANADA TRANSPORT LIMITED Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"CANADA TRANSPORT LIMITED\" is 11242 Est, Boul.Gouin, Rivière-des-Prairies, Montreal.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, Attorneys for the Company.EVERETT KENNEDY LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province dc Quebec, de la compagnie « EVERETT KENNEDY LTD.-, esta/s QUEBEC VEGETABLES DISTRIBUTORS INC.».rang St-André, Napierville, Prov.Que.1a:s procureurs de lu compagnie.Paquette, Paquette, 56281-o Perreault & Rivet.THEODORE D.GAAIRLIN Prenez avis que l'adresse dans la province de Québec de « THEODORE D.GAMBLIN » est 3600 boul.Hamel, Québec.Le procureur.56282-0 Jacques Lanolois.EVERETT KENNEDY LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec of \"EVERETT KENNEDY LTD.\", is c/o QUEBEC VEGETABLES DISTRIBUTORS INC., Rang St-André, Napierville, Prov.Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56181-o Attorneys for the Company.THEODORE D.GAMBLIN Notice is given that the address in the Province of Québec of \"THEODORE D.GAMBLIN\" is 3600 Hamel Blvd., Québec.Jacques Langlois, 56282-0 The Attorney.LINE HAUL LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, dc la compagnie « LINE HAUL LTD.» est 200 ouest, rue St-Jacques.Suite 905, Montreal.Prov.Québec.H2Y 1M1.Lej procureurs de la compagnie.Paquette.Paquette, 56283-0 Perreault & Rivet.LINE HAUL LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"LINE HAUL LTD.\" is 200 St.James St.W.Suite 905, Montreal, Prov.Québec.H2Y 1M1.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56283-o Attorneys for the Company.W.F.& W.D.SCOTT LIMITED Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, dc la compagnie « W.F.& W.D.SCOTT LIMITED », permis No 17520-V est 200 ouest, rue St-Jacqucs.Suite 905, Montréal, Prov.Québec.H2Y1M1.Les procureurs de la compagnie.Paquette.Paquette.56284-0 Perreault & Rivet.W.F.& W.D.SCOTT LIMITED Notice is given that the address, for the Province of Quebec, of \"W.F.& W.D.SCOTT LIMITED\", permit No.17520-V is 200 St.James St.W\u201e Suite 905, Montreal, Prov.Quebec.H2Y lMl.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56284-o Attorneys for the Company.C & H STEEL INDUSTRIES LIMITED Avis est donné que l'adresse, pour la province de ;,S,l.aY,S?mPa8n>c « G & H STEEL INDUSTRIES LIMITED » est 700, Chemin St-Régis, St-Constant, Que.Le procureur de la compagnie.56337-0 Guy Parente au.G & II STEEL INDUSTRIES LIMITED Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"G & H STEEL INDUSTRIES LI-MlTED\" is 700 St-Régis Road, St-Constant, P.Q.56337-0 Gut Parenteau, Attorney for the company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 1937 MACK'S TRANSFER LIMITED Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « MACK'S TRANSFER LIMITED » est 212, rue Bloomfield, Outremont, Prov.Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 56285-0 Pfrreault & Rivet.MACK'S TRANSFER LIMITED Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"MACK'S TRANSFER LIMITED\", is 212 Bloomfield St., Outremont, Prov.Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56285-0 Attorneys for the Company.PROTRAIL RENTALS LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « PROTRAIL RENTALS LTD.» est 2514, boul.Rosemont, Montreal, Prov.Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 56286-q Perreault & Rivet.PROTRAIL RENTALS LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"PROTRAIL RENTAL LTD\", is 2514, Rosemont Blvd., Montreal, Prov.Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56286-0 Attorneys for the Company.RYDER TRUCK LINES INC.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « RYDER TRUCK LINES INC.», permis No 22150-V, est 200 ouest, rue St-Jacques.Suite 905.Montréal, Prov.Québec, H2Y 1 Ml.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 56287-o Perreault & Rivet.RYDER TRUCK LINES INC.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"RYDER TRUCK LINES INC.\", permit No.22150-V is 200 St.James St.W., Suite 905, Montreal.Prov.Québec, H2Y 1M1.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56287-0 Attorneys for the Company.DIVERSIFIED PRODUCTS TRUCKING CORP.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « DIVERSIFIED PRODUCTS TRUCKING CORP.» est a/s ST-ARNAUD & BERGEVIN, 410, rue St-Nicolas, Montréal 125, Québec.Les procureurs de la compagnie.Paquette, Paquftte, 5632U-o Perreault & Rivet.DIVERSIFIED PRODUCTS TRUCKING CORP.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"DIVERSIFIED PRODUCTS TRUCKING CORP.\", is c/o ST-ARNAUD & BERVGEVIN, 410 St.Nicolas St., Montreal 125, Québec.Paquette, Paquette, Perreault, & Rivet, 56320-o Attorneys for the Company.TRAIN TRAILER RENTALS (QUEBEC) LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « TRAIN TRAILER RENTALS (QUEBEC) LTD.» est 560, rue Landreville, suite 2A, île des Soeurs, MU.201.Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 56321-0 Perreault & Rivet.TRAIN TRAILER RENTALS (QUEBEC) LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"TRAIN TRAILER RENTALS (QUEBEC) LTD., is 560 Landreville, St., suite 2A, Nuns Island, Mtl.201, Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56321-0 Attorneys for the Company.J.E.THOMPSON TRANSPORT INC.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « J.E.THOMPSON TRANSPORT INC.», permis No 6483-V est 200 ouest rue St-Jacques, suite 905, Montréal, province de Québec.H2Y 1M1 Les procureurs de la compagnie.Paquette, Paquette.56374-o Perreault & Rivet.J.E.THOMPSON TRANSPORT INC.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"J.E.THOMPSON TRANSPORT INC.\", permit No.6483-V is 200 St.James St.W., Suite 905, Montreal, Province of Québec.H2Y lMl Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56374-0 Attorneys for the company. 1938 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106.No.10 BLUE BIRD MOVING & STORAGE LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « BLUE BIRD MOVING & STORAGE LTD.» est: 200 ouest, rue St-Jacques, suite 905, Montréal.Québec.H2Y 1M1 (842-1864).Les procureurs de la compagnie.Paquette.Paquette, 56425-0 Perreault & Rivet.BLUE BIRD MOVING & STORAGE LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"BLUE BIRD MOVING & STORAGE LTD.\", is 200 St.James St.West, suite 905, Montreal, Québec H2 Y 1M1 (842-1864).Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56425-0 Attorneys for the Company.Charte \u2014 demandes d'abandon de Charter \u2014 Applications for Surrender of ANDRE AUCLAIR & ASSOCIES INC.Prenez a vis que « ANDRÉ AUCLAIR & ASSOCIES INC.\" s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives en vue d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 20 février 1974.Le procureur dc la compagnie.56290-o Jacques Laurent.ANDRE AUCLAIR & ASSOCIES INC.Take notice that \"ANDRÉ AUCLAIR & ASSOCIES INC.\" will apply to the Minister of the Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charier.Montreal, February 20, 1974.Jacques Laurent, 56290-o Attorney of the Company.LA CIE DE GESTION GISBEC INC.Prenez avis que la compagnie « LA CIE DE GESTION GISBEC INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Lê secrétaire.56291-o Ray Lussier.LA CIE DE GESTION GISBEC INC.Notice is given that \"LA CIE DE GESTION GISBEC INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Ray Lussieh, 56291 Secretary.A.FOGEL ENTERPRISES LTEE Avis est donné que la compagnie, A.FOGEL ENTERPRISES LTEE », une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, 21e jour de décembre, 1973.Le secrétaire, 56292-o W.Foc el.GERVAIS CHAISE & TABLE LTEE GERVAIS CHAIR & TABLE LTD.Conformément aux dispositions de la Loi des compagnies, « GERVAIS CHAISE & TABLE LTEE -GERVAIS CHAIR & TABLE LTD.» donne par les présentes avis de son intention dc demander au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte, l'annulation de sa charte et la dissolution de la compagnie.Montréal.P.Q., ce 14e jour de février.1974.Le secrétaire.a6295-o Pierre P.Sa varia.A.FOGEL ENTERPRISES LTEE Notice is given that \"A.FOGEL ENTERPRISES LTEE\", incorporated under the Companies Act, and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter in conformity with the provisions of the Companies Act.Dated in Montreal, the 21st day of December, 1973.W.Fog el, 56292 Secretary.GERVAIS CHAISE & TABLE LTEE GERVAIS CHAIR & TABLE LTD.Under the provisions of the Companies Act, \"GERVAIS CHAISE & TABLE LTEE \u2014 GERVAIS CHAIR & TABLE LTD.\" hereby gives notice that it intends to apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender the charter of the company, for cancellation of the charter and for the dissolution of the company.Montreal.P.Q., this 14th day of February, 1974.Pierre P.Savaria, 56295-0 Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 1930 FONDATION DE L'HOPITAL DU SACRE-COEUR Avis est donné que la compagnie « FONDATION DE L'HOPITAL DU SACRE-COEUR » s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie, Monette, Clerk, Michaud, Barakett.56293-0 lévksque et Guérette.FONDATION DE L'HOPITAL DU SACRE-COEUR Take notice that the company \"FONDATION DE L'HOPITAL DU SACRE-COEUR\" will request from the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the permission to abandon its charter.Monette, Clerk, Miciiaud, Barakett, lévesque and guérette, 56293-0 Attorneys for the company.LA LALIBERTEE LTEE Avis est par les présentes donné que la compagnie « LA LIBERTES LTEE », constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Montréal, Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Fait à Montréal.Québec, ce 25e jour de janvier 1974.Les procureurs du requérant.56296 Batshaw & Solomon.LA LALIBERTEE LTEE Notice is hereby given that \"LA LIBERTEE LTEE\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in Montreal, Quebec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated in Montreal, Québec, this 25th dav of January, 1974.Batshaw & Solomon, 56296-o Attorneys for the applicant.MODEL AUTO ELECTRIC LTEE Avis est donné qu'en vertu tie la première partie de la Loi des compagnies, « MODEL AUTO ELECTRIC LTEE » constituée en corporation sous la première partie de la Loi des compagnies le 10 novembre 1965 et ayant son siège social à 851, rue Saint-Georges à Saint-Jérôme, demandera la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie.56297-o Forget & Rochon.MODEL AUTO ELECTRIC LTEE Notice is herebv given that under Part I of the Companies Act, \"MODEL AUTO ELECTRIC LTEE\" having its head office at 851 St.Georges Street, St.Jérôme, incorporated under Part I of the Companies Act on November 10, 1965, will make an application for leave to surrender its charter.Forget & Rochon, 56297-0 Attorneys for the company.QUEBEC INDUSTRIAL GAS LTD.GAZ INDUSTRIEL DU QUEBEC LTEE Prenez avis que la compagnie « QUEBEC INDUS-TRIAL GAS LTD.\u2014 GAZ INDUSTRIEL DU QUE-BEC LTEE », une compagnie dûment incorporée en vertu de la Loi des compagnies minières et ayant son siège social à Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte, selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Calgary, Alberta, ce 7e jour de janvier 1974.Le secrétaire.56298-0 L.A.Sills.PLANIFONDS INC.Prenez avis que « PLANIFONDS INC » s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives en vue d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 20 février 1974.L'avocat de la compagnie, 56299-o Jacques Laurent.QUEBEC INDUSTRIAL GAS LTD.GAZ INDUSTRIEL DU QUEBEC LTEE Notice is hereby given that \"QUEBEC INDUSTRIAL GAS LTD.\u2014GAZ INDUSTRIEL DU QUEBEC LTEE\", a corporation incorporated under the Mining Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives in the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Calgarv, Alberta, this 7th day of January, 1974.L.A.Sills, 56298-0 Secretary.PLANIFONDS INC.Take notice that \"PLAND70NDS INC.\" will apply to the Minister of the Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, February 20, 1974.Jacques Laurent, 56299-0 Attorney for the Company. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 FORMATRIX INC.Prenez avis que la compagnie « FORMATRIX INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 56294-0 Mb J.Guy Charbonneau, notaire.FORMATRIX INC.Notice is given that \"FORMATRIX INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Mtre J.Guy Charbonneau, notary, 56294-0 Attorney for the company.CAPITAL WIRE CLOTH EASTERN LIMITED Avis est donné que la compagnie « CAPITAL WIRE CLOTH EASTERN LIMITED », ayant son siège social à St-Romuald d'Etchemin, province de Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province, la permission d'abandonner sa charte.St-Romuald d'Etchemin, ce lie jour de février 1974.(Sceau) Le secrétaire.56328-0 .1.P.Morris.CAPITAL WIRE CLOTH EASTERN LIMITED Notice is given that the company \"CAPITAL WIRE CLOTH EASTERN LIMITED\" having its head office in St.Romuald d'Etchemin, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province for leave to surrender its charter.St.Romuald d'Etchemin, this 11th day of February, 1974.(Seal) J- P- Morris.56328-o Secretary.COSMOS PRINTING & DISTRIBUTING INC.Avis est par les présentes donné que « COSMOS PRINTING & DISTRIBUTING INC.» ayant son bureau chef dans les cité et district de Montéal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte selon la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce lie jour de février, 1974.Les procureurs de la requérante, Stein & Stein.800, boul.Dorchester O., Suite 1430, Montréal, P.Q.56329-0 COSMOS PRINTING & DISTRIBUTING INC.Notice is hereby given that \"COSMOS PRINTING & DISTRIBUTING INC.\", having its head office in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies' Act.Montreal, the 11th day of February, 1974.Stein & Stein, Attorneys for Petitioner.S00 Dorchester Blvd.W., Suite 1430, Montreal.P.Q.56329-0 GECO (QUEBEC) LIMITED Avis est par les présentes donné que la compagnie « GECO (QUEBEC) LIMITED », corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, ayant son siège social dans la ville de Montréal, Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province, la permission d'abandonnei sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, Québec, ce 9e jour de mars 1974.Le président, 56344-0 Per Hall.GECO (QUEBEC) LIMITED Notice is hereby given tliat \"GECO (QUÉBEC) LIMITED\", a corporation constituted under Paît I of the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the terms of the Companies Act as and from a date to be fixed by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.Montreal, Québec, this 9th day of March, 1974.Per Hall, 56344-0 President.MONTREAL IMPORTING LIMITED Avis est donné que la compagnie « MONTREAL IMPORTING LIMITED » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 26 février 1974.Le procureur de la requérante, 56345-0 L.G.MacGreqor, c.r.MONTREAL IMPORTING LIMITED Notice is given that \"MONTREAL IMPORTING LIMITED\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, this 26th day cf February, 1974.L.G.MacGregor, q.c., 56345-0 Attorney for the Company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 1941 SERVICE S.A.V.E.INC.Avis est donné que la compagnie « SERVICE S.A.V.E.INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 56300-o Carl Thbrrien.SEAWAY STORAGE INC.Avis est donné que la compagnie « SEAWAY STORAGE INC.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Lachine, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté ce 31e jour de janvier 1974.Le secrétaire, 56357 J.B.Jolley.BELISLE FRERES LIMITEE Avis est donné que la compagnie « BELISLE FRERES LIMITEE» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 28 février 1974.Le procureur de la compagnie, 56375-o Pierre H.Archambault, notaire.C.H.E.OUTFITTERS INC.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie «C.H.E.OUTFITTERS INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Hull, le 12 février 1974.Le procureur de la compagnie, 56376-0 Jacques Libersan.SERVICE S.A.V.E.INC.Notice is given that \"SERVICE S.A.V.E.INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Carl Therrien, 56300 Attorney for the Company.SEAWAY STORAGE INC.Notice is given thai \"SEAWAY STORAGE INC.\" a corporation incorporated pursuant to the Companies Act, and having its head office in the City of Lachine, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter in conformity with the provisions of the Companies Act.Dated this 31st day of January, 1974.J.B.Jolley, 56357-o Secretary.BELISLE FRERES LIMITEE Notice is given that \"BELISLE FRERES LIMITEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter.Montreal, February 28, 1974.Pierre H.Archambault, notary, 56375-0 Attorney for the Company.C.H.E.OUTFITTERS INC.Notice is given that \"C.H.E.OUTFITTERS INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Hull, February 12, 1974.Jacques Libersan, 56376-0 Attorney for the Company.LES ECURIES BAGATELLES LTEE Prenez avis que la compagnie « LES ECURIES BAGATELLES LTEE » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 56377-o Jean Goyette, c.r.LES ECURIES BAGATELLES LTEE Notice is hereby given that \"LES ECURIES BAGATELLES LTEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Jean Goyette, q.c, 56377-0 Attorney for the Company.OEUVRE DES LOISIRS DE LA S.S.J.B.DE RIVIERE BLANCHE INC.Prenez avis que la compagnie « OEUVRE DES LOISIRS DE LA S.S.J.B.DE RIVIERE BLANCHE INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Matane, 25 février 1974.Le procureur de la requérante.56378-0 G.Alex Lebel.OEUVRE DES LOISIRS DE LA S.S.J.B.DE RIVIERE BLANCHE INC.Take notice that the company \"OEUVRE DES LOISIRS DE LA S.S.J.B.DE RIVIERE BLANCHE INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for a permission to surrender its charter.Matane February 25th, 1974.G.Alex Lebel, 56378-0 Attorney for the Company. 1942 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.March 9, 1974.Vol.106.No.10 Divers Compagnies Miscellaneous Companies LA FERME AVICOLE LES BUISSONS INC.U compagnie «LA FERME AVICOLE LES BUISSONS INC.» donne avis qu'elle a change le nombre dc ses administrateurs de 4 à 3.Le tecrêtaire, Jean-Claude Tremblay.56316-0 731793 GREENSHIELDS LTD.La compagnie « GREENSHIELDS LTD.» donne avis qu'elle a réduit de 12 à 11 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire-trésorier, F.D.Teatro.56317 12510-61 WORLD MOSAICS INC.La compagnie « WORLD MOSAICS INC.» donne avis qu'elle a diminué de 4 à 3 le nombre des administrateurs.La secrétaire, Diane Diener.56318 10302-60 CO-MATIC INC.La compagnie « CO-MATIC INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 7.La secrétaire, Mme Irène L.Côte.56322-o 3095-64 UNIMEDIA INC.La compagnie « UNIMEDIA INC.\u2022 donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.Le secrétaire.Camille Corbeil.56325-0 733659 UNITED SHIRT CORP.La compagnie « UNITED SHIRT CORP.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire.Stephen Kape.56326 11477-54 SIDBEC-FERUNI INC.La compagnie « SIDBEC-FERUNI INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 7.Le secrétaire.Pierre Sauvé.56350-o 737791 LA FERME AVICOLE LES BUISSONS INC.Notice is given that \"LA FERME AVICOLE LES BUISSONS INC.» has reduced the number of its directors from 4 to 3.Jean-Claude Tremblay, Secretary.56316 731793 GREENSHIELDS LTD.Notice is given that \"GREENSHIELDS LTD.\" has changed the number of its directors from 12 to 11.F.D.Teatro, Secretary-Treasurer.12510-61 56317-o WORLD MOSAICS INC.Notice is given that \"WORLD MOSAICS INC.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.56318-o Diane Diener, Secretary.10302-60 CO-MATIC INC.Notice is given that \"CO-MATIC INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 7.56322 Mrs.Irène L.Côté, Secretary.3ll!l'»-(il UNIMEDIA INC.Notice is given that \"UNIMEDIA INC.\" has increased the number of its directors from 3 to 5.56325 Camille Corbeil, Secretary.733659 UNITED SHIRT CORP.Notice is given that \"UNITED SHIRT CORP.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.56326-0 Stephen Kape.Secretary.11477-54 SIDBEC-FERUNI INC.Notice is given that \"SIDBEC-FERUNI INC.\" has changed the number of its directors from 5 to 7.56350-o Pierre Sauvé, Secretary.737791 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 1943 LA GRANGE D'AUBAINES S.H.INC.La compagnie « LA GRANGE D'AUBAINES S.H.INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Sam Crudo.56346-o 737667 LA GRANGE D'AUBAINES S.H.INC.Notice is given that \"LA GRANGE D'AUBAINES S.H.INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Sam Crudo, Secretary.56346-0 737667 JODOIN, LAMARRE, PRATTE & ASSOCIES INC.JODOIN, LAMARRE, PRATTE AND ASSOCIATES INC.La compagnie « JODOIN.LAMARRE, PRATTE & ASSOCD3S INC.\u2014 JODOIN, LAMARRE, PRATTE AND ASSOCIATES INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre dc ses administrateurs dc 4 à 3.Le secrétaire, Gérard Pratte.56347-0 4150-63 JODOIN, LAMARRE, PRATTE & ASSOCIES INC.JODOIN, LAMARRE, PRATTE AND ASSOCIATES INC.Notice is given that \"JODOIN, LAMARRE, PRATTE & ASSOCIES INC.\u2014 JODOIN, LAMARRE, PRATTE AND ASSOCIATES INC.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.Gérard Pratte, Secretary.56347-0 4150-63 LES IMMEUBLES GBH LIMITEE La compagnie « LES IMMEUBLES GBH LIMITEE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.Le secrétaire, Robert Chevrier.56349-0 4113-66 LES IMMEUBLES GBH LIMITEE Notice is given that \"LES IMMEUBLES GBH LIMITEE\" has changed the number of its directors from 5 to 3.Robert Chevrier, Secretary.56349-0 4113-66 TRANS-CANADA DIRECTORIES (QUE.) LTD.LES ANNUAIRES TRANS-CANADA (QUE.) LTFE La compagnie « TRANS-CANADA DIRECTORIES (QUE.) LTD.\u2014 LES ANNUAIRES TRANSCANADA (QUE.) LTEE » donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Sydney Morris.56390 7-65 ASSELIN, BENOIT, BOUCHER, DUCHARME, LAPOINTE INC.La compagnie « ASSELIN, BENOIT, BOUCHER, DUCHARME, LAPOINTE INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 10.Le secrétaire, Robert Garneau.5639l-o 3250-65 TRANS-CANADA DIRECTORIES (QUE.) LTD.LES ANNUAIRES TRANS-CANADA (QUE.) LTEE Notice is given that \"TRANS-CANADA DIRECTORIES (QUE.) LTD.\u2014 LES ANNUAIRES TRANS-CANADA (QUE.) LTEE\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Sydney Morris, Secretary.56390-o 7-65 ASSELIN, BENOIT, BOUCHER, DUCHARME, LAPOINTE INC.Notice is given that \"ASSELIN, BENOIT, BOUCHER, DUCHARME, LAPOINTE INC.\" has changed the number of its directors from 5 to 10.Robert Garneau, Secretary.56391 3250-65 MULTIVEST REALTIES CORPORATION LA CORPORATION DES IMMEUBLES MULTIVEST La compagnie « MULTIVEST REALTIES CORPORATION \u2014 LA CORPORATION DES IMMEUBLES MULTIVEST » donne avis qu'elle augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Dov Kravetz.56392 737325 MULTIVEST REALTIES CORPORATION LA CORPORATION DES IMMEUBLES MULTIVEST Notice is given that \"MULTIVEST REALITES CORPORATION \u2014 LA CORPORATION DES IMMEUBLES MULTIVEST\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Dov Kravetz, Secretary.56392-0 737325 19-44 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9.1974, Vol.106, No.10 VANGUARD SCHOOL OF QUEBEC LIMITED ECOLE VANGUARD QUEBEC LIMITEE La corporation « VANGUARD SCHOOL OF QUEBEC LIMITED \u2014 ECOLE VANGUARD QUEBEC LIMITEE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 7.Le secrétaire, Roland Malo.56348-0 731083 GROUPEX DISTRIBUTION INC.La compagnie « GROUPEX DISTRIBUTION INC.8 donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 6 à 7.Le secrétaire, Emile Cousineau.56379-0 4464-68 K.L.K.INC.La compagnie « K.L.K.INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 4.Le secrétaire, Serge Desrochers.56383-0 5540-69 AGF MONTREAL INVESTMENT MANAGEMENT INC.AGF GESTION DE PLACEMENTS MONTREAL INC.La compagnie < AGF MONTREAL INVESTMENT MANAGEMENT INC.\u2014 AGF GESTION DE PLACEMENTS MONTREAL INC.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Paul F.Dingle.56389 1240-71 CANTERRA INC.La compagnie « CANTERRA INC.» donne avis qu'elle a diminué de 5 à 3 le nombre dc ses administrateurs.Le président.Manas Chatterjee.56393 746050 CENTRE FRANCOIS-MICHELLE La corporation « CENTRE FRANCOIS-MICHELLE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 11 à 7.Le secrétaire, André Castonguay.56394-0 2973-71 COURRIER LAVAL LTEE La compagnie « COURRIER LAVAL LTEE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 7 à 5.Le secrétaire, Camille Corbeil.56395-0 731536 VANGUARD SCHOOL OF QUEBEC LIMITED ECOLE VANGUARD QUEBEC LIMITEE Notice is given that \"VANGUARD SCHOOL OF QUEBEC LIMITED - ECOLE VANGUARD QUEBEC LIMITEE\" has changed the number of its directors from 3 to 7.Roland Malo, Secretary.56348-o 731083 GROUPEX DISTRIBUTION INC.Notice is given that \"GROUPEX DISTRIBUTION INC.\" has changed the number cf its directors from 6 to 7., Emile Cousineau, Secretary.56379 4464-68 K.L.K.INC.Notice is given that \"K.L.K.INC.\" has changed the number of its directors from 5 to 4.Serge Desrochers, Secretary.56383 5540-69 AGF MONTREAL INVESTMENT MANAGEMENT INC.AGF GESTION DE PLACEMENTS MONTREAL INC.Notice is given that \"AGF MONTREAL INVESTMENT MANAGEMENT INC.\u2014 AGF GESTION DE PLACEMENTS MONTREAL INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 5.Paul F.Dingle, Secretary.56389-0 1240-71 CANTERRA INC.Notice is given that \"CANTERRA INC.\" has changed the number of its directors from 5 to 3.Manas Chatterjee.President.56393-0 746050 CENTRE FRANCOIS-MICHELLE Notice is given that \"CENTRE FRANCOIS-MICHELLE\", has changed the number of its directors from 11 to 7.André Castonguay, Secretary.56394 2973-71 COURRIER LAVAL LTEE Notice is given that \"COURRIER LAVAL LTEE\" has changed the number of its directors from 7 to 5.56395 Camille Corbeil, Secretary.731536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 1945 CRAWLEY & McCRAKEN COMPANY LIMITED CRAWLEY & McCRAKEN COMPANY LIMITED La compagnie « CRAWLEY & McCRAKEN COMPANY LIMITED » donne avis qu'elle a diminué de 9 à 7 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire.H.B.Swan.56396 1545-18 DIALIN CRANE SERVICE LTD.SERVICE DE GRUES DIALIN LTEE La compagnie < DIALIN CRANE SERVICE LTD.\u2014 SERVICE DE GRUES DIALIN LTEE » donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.La secrétaire.Mme Gladys Potts.56397 716735 Notice is given that \"CRAWLEY & McCRAKEN COMPANY LIMITED\" has changed the number of its directors from 9 to 7.H.B.Swan, Secretary.56396-0 1545-18 DIALIN CR4NE SERVICE LTD.SERVICE DE GRUES DIALIN LTEE Notice is given that \"DIALIN CRANE SERVICE LTD.\u2014 SERVICE DE GRUES DIALIN LTEE\" has changed the number of its directors from 3 to 4.56397-0 Mrs.Gladys Potts, Secretary.716735 LES PLACEMENTS FERNAND DOYON INC.FERNARD DOYON INVESTMENTS INC.La compagnie « LES PLACEMENTS FERNAND DOYON INC.\u2014FERNAND DOYON INVESTMENTS INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.La secrétaire, Mireille Doyon.56398-0 733242 FOOD SERVICES LIMITED La compagnie « FOOD SERVICES LIMITED» donne avis qu'elle a diminué de 9 à 7 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, H.B.Swan.56399 898-63 CH.HEIST LTEE La compagnie « CH.HEIST LTEE » donne avis qu'elle a diminué de 5 à 3 le nombre de ses administrateurs.Le président, CH.Heist.56400 4897-67 IMPERIAL PANTS CO.LTD.La compagnie « IMPERIAL PANTS CO.LTD.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Bernard Sternklar.56401 12286-57 KATES LTD.La compagnie « KATES LTD.» donne avis qu'elle a diminué de 6 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Ralph Kronick.56404 13287-58 LES PLACEMENTS FERNAND DOYON INC.FERNARD DOYON INVESTMENTS INC.Notice is given that \"LES PLACEMENTS FERNAND DOYON INC.\u2014FERNAND DOYON INVESTMENTS INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Mireille Doyon, Secretary.56398 733242 FOOD SERVICES LIMITED Notice is given that \"FOOD SERVICES LIMITED\" has changed the number of its directors from 9 to 7.56399-o H.B.Swan, Secretary.898-63 CH.HEIST LTEE Notice is given that \"CH.HEIST LTEE\" has changed the number of its directors from 5 to 3.56400-o CH.Heist, President.4897-67 IMPERIAL PANTS CO.LTD.Notice is given that \"IMPERIAL PANTS CO.LTD.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Bernard Sternklar, Secretary.56401-o 12286-57 KATES LTD.Notice is given that \"KATES LTD.\" has changed the number of its directors from 6 to 5.Ralph Kronick, Secretary.56404-o 13287-58 1046 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1971,, Vol.106, No.10 MERCERIE COME BERTRAND INC.La compagnie « MERCERIE COME BERTRAND INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire.Marcel Bertrand.56405-O 4620-68 METROHEAT INDUSTRIES LTD.La compagnie «METROHEAT INDUSTRIES LTD.» donne avis qu'elle a augmenté de 4 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire.Nathan Abrams.56406 1985-65 METROPOLITAN OIL & CAS INDUSTRIES INC.La compagnie « METROPOLITAN OIL & GAS INDUSTRIES INC.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Nathan Abrams.56407 1060-39 MURRAY'S RESTAURANTS LIMITED La compagnie « MURRAY'S RESTAURANTS LIMITED » donne avis qu'elle a diminué de 9 à 7 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire.H.B.Swan.56408 901-26 NANCYTEC LTEE NANCYTEC LTD.La compagnie « NANCYTEC LTEE \u2014 NANCY-TEC LTD.» donne avis qu'elle a augmente dc 3 à 4 le nombre dc ses administrateurs.Le secrétaire, Morris Goodman.56409 61.71 PEERLESS CLOTHING MFG.COMPANY La compagnie « PEERLESS CLOTHING MFG.I OMPAN i donne avis qu'elle a augmenté de t à S le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Irving Zwirek.56411 14452-62 SCOOP FASHIONS INC.La compagnie « SCOOP FASHIONS INC.» donne avis qu'elle a diminué de 4 à 3 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire.Viola Larry.56413 1107-67 MERCERIE COME BERTRAND INC.Notice is given that \"MERCERIE COME BERTRAND INC.\" has changed the number of its directors from 4 to 3._ _ Marcel Bertrand, Secretary.56405 «20-68 METROHEAT INDUSTRIES LTD.Notice is given that \"METROHEAT INDUSTRIES LTD.\" has changed the number of its directors from 4 to 5.Nathan Abrams, Secretary.56406-o 1985-65 METROPOLITAN OIL & GAS INDUSTRIES INC.Notice is given that \"METROPOLITAN OIL & GAS INDUSTRIES INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 5.Nathan Abrams, Secretary.56407-o 1060-39 MURRAY'S RESTAURANTS LIMITED Notice is given that \"MURRAY'S RESTAURANTS LIMITED\" has changed the number of its directors from 9 to 7.H.B.Swan, Secretary.56408-o 901-26 NANCYTEC LTEE NANCYTEC LTD.Notice is given that \"NANCYTEC LTEE \u2014 NANCYTEC LTD.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Morris Goodman, Secretary.56409-O 61-71 PEERLESS CLOTHING MFG.COMPANY Notice is given that \"PEERLESS CLOTHING MFG.COMPANY\" has changed the number of its directors from 4 to 5.Irving Zwirek, Secretary.56411-0 14452-62 SCOOP FASHIONS INC.Notice is given that \"SCOOP FASHIONS INC.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.56413-o Viola Larry.Secretary.1107-67 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 1947 INTERNATIONAL ROMAN HEALTH SPA LTD.SOURCES DE SANTE ROMAINE INTERNATIONALE LTEE La compagnie « INTERNATIONAL ROMAN HEALTH SPA LTD.\u2014SOURCE DE SANTE INTERNATIONALE LTEE » donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le président, René A.Dubé.56402 737281 INTERNATIONAL ROMAN HEALTH SPA LTD.SOURCES DE SANTE ROMAINE INTERNATIONALE LTEE Notice is given that \"INTERNATIONAL ROMAN HEALTH SPA LTD.\u2014SOURCE DE SANTE ROMAINE INTERNATIONALE LTEE\" has changed the number of its directors from 3 to 4.René A.Dubé, President.56402-o 737281 NESBITT, THOMSON AND COMPANY, LIMITED NESBITT, THOMSON ET COMPAGNIE, LIMITEE La compagnie « NESBITT, THOMSON AND COMPANY LIMITED \u2014 NESBITT, THOMSON ET COMPAGNIE, LIMITEE » donne avis qu'elle a diminué de 27 à 25 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire-trésorier, K.W.M c arthur.56410 5149-52 NESBITT, THOMSON AND COMPANY, LIMITED NESBITT, THOMSON ET COMPAGNIE, LIMITEE Notice is given that \"NESBITT, THOMSON AND COMPANY, LIMITED \u2014 NESBITT, THOMSON ET COMPAGNIE, LIMITEE\" has changed the number of its directors from 27 to 25.K.W.Mcarthur, Secretary-Treasurer.56410-O 5149-52 QUEBEC METAL POWDERS LIMITED LES POUDRES METALLIQUES DU QUEBEC, LIMITEE La compagnie « QUEBEC METAL POWDERS LIMITED \u2014 LES POUDRES METALLIQUES DE QUEBEC, LIMITEE » donne avis qu'elle a augmenté de 8 à 9 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire.Patrick H.Bowen.56412 4910-67 SOCIETE TRIPLE A INC.La « SOCIETE TRIPLE A INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4à7.Le secrétaire.Jean-Paul Préfontaine.56414-0 731632 SPORTS EXPERTS INC.La compagnie « SPORTS EXPERTS INC.> donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 15.Le secrétaire, Charles Rouillard.56415-o 508-66 QUEBEC METAL POWDERS LIMITED LES POUDRES METALLIQUES DU QUEBEC, LIMITEE Notice is given that \"QUEBEC METAL POWDERS LIMITED \u2014 LES POUDRES METALLIQUES DU QUEBEC, LIMITEE\" has changed the number of its directors from 8 to 9.Patrick H.Bowen.Secretary.56412-o 4910-67 SOCIETE TRIPLE A INC.Notice is given that \"SOCIETE TRIPLE A INC.\" has changed the number of its directors from 4 to 7.56414 Jean-Paul Préfontaine, Secretary.731632 SPORTS EXPERTS INC.Notice is given that \"SPORTS EXPERTS INC.\" has changed the number of its directors from 5 to 15.56415 Charles Rouillard, Secretary.508-66 STEEL & STAINLESS FABRICATORS LIMITED La compagnie « STEEL & STAINLESS FABRICATORS LIMITED » donne avis quelle a augmenté de 3 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, William M.Phipps.56416 5307-63 STEEL & STAINLESS FABRICATORS LIMITED Notice is given that \"STEEL & STAINLESS FABRICATORS LIMITED\" has changed the number of its directors from 3 to 5.William M.Phipps, Secretary.56416-o 5307-63 1948 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 9.1974.Vol.106, No.10 VERMETTE & F1I.S I.TEE VERMETTE & SONS LTD.La compagnie « VERMETTE & FILS LTEE \u2014 VERMETTE & SONS LTD.» donne avis qu'elle a changé le nombre dc ses administrateurs dc 6 à 5.Le secrétaire.Bertrand Vermette.56417-0 5321-44 VERMETTE & FILS LTEE VERMETTE & SONS LTD.Notice is given that \"VERMETTE & FILS LTEE \u2014 VERMETTE & SONS LTD.\" has changed the number of its directors from 6 to 5.Bertrand Vermette.Secretary.56417 5321-44 Sièges sociaux Head Offices BERJO INC.Avis est par les présentes donné que « BERJO INC.>, constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu de la première partie de la Loi des compagnies en date du 8 janvier 1974.et ayant son siège social .Un- la ville de Laval, district de Montréal province de Québec, où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au boulevard Cartier, coin nord-est, Ampère, l'a transporté au numéro 300 de la 87e avenue, Chpmedey.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Laval, ce 31e jour de janvier 1974.(Sceau) Le secrétaire, 56301-o Jean-Louis Stockli.BERJO INC.Notice is hereby given that \"BERJO INC.\", incorporated by letters patent issued under Part I of the Companies Act dated January 8, 1974, and having its head office in the City of Laval, district of Montreal, Province of Québec, where its head office was located until today at Cartier Boulevard, Corner northeast, Ampère, has transferred said office to 300-87th Avenue, Chomedey.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Laval, this 31st day of January, 1974.(Seal) Jean-Louis Stockli, 56301-o Secretary.BUDGET FUELS INC.HUILES BUDGET INC.Avis est donné que la compagnie « BUDGET FUELS INC.\u2014 HUILES BUDGET INC.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège à Montréal, 5480 Paré, Montréal, Québec, a établi son bureau au numéro 7200 Hutchison, Montréal, Québec.Daté à Montréal, le 19 février 1974.Le secrétaire, 56303-o Ellis Irving.BUDGET FUELS INC.HUILES BUDGET INC.Notice is hereby given that \"BUDGET FUELS INC.\u2014 HUILES BUDGET INC.\", incorporated under Part I of the Québec Companies Act, has moved ist head office from 5480 Paré, Montreal, Québec, to 7200 Hutchison, Montreal, Québec.Dated at Montreal, February 19, 1974.Ellis Irving, 56303-o Secretary.CANTINE PASCAL INC.Avis est donné que la compagnie « CANTINE PASCAL INC.», constituée en corporation en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies par lettres patentes portant la date du 16 janvier 1974, et ayant son siège social dans la ville de St-Hubert, où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 4605, rue Thibault, l'a transporté au numéro 6305 Chemin de la Savane.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, le 11 février 1974.(Sceau) Le président.56304-o Real Lajeunesse.CANTINE PASCAL INC.Notice is hereby given that \"CANTINE PASCAL INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated January 16, 1974, has moved its head office from 4605 Thibault Street in the City of Si-Hubert to 6305 de la Savane Road in the City of St-Hubert.From the date of this notice, the said office shall be considered by the company as its head office.Given at Montreal.February 11, 1974.(Seal) Real Lajeunesse, 56304-o President. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, »° 10 1949 LES BOITES DE CARTON VERSATILE, MONTREAL INC.VERSATILE PAPER BOXES, MONTREAL INC.Avis vous est donné que la compagnie « LES BOITES DE CARTON VERSATILE.MONTREAL INC.\u2014 VERSATILE PAPER BOXES, MONTREAL INC.», constituée en corporation par lettres patentes datées du 17 décembre 1973, a son siège social au numéro 642, boul.Guimond, à Longueuil, province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Cilé Lasallc, ce 18e jour de décembre 1973.Le président, 56302-o M.Roger Defoy.LES BOITES DE CARTON VERSATILE.MONTREAL INC.VERSATILE PAPER BOXES, MONTREAL INC.Notice is given that \"LES BOITES DE CARTON VERSATILE, MONTREAL INC.\u2014 VERSATILE PAPER BOXES, MONTREAL INC.\", incorporated by letters patent dated December 17, 1973, has its head office at 642 Guimond Boulevard, in Longueuil, Province of Québec.From the date of this notice, the said office shall be considered by the company as its head office.Given in the Citv of Lasallc.this 18th day of December, 1973.Roger Defoy, 56302 President.330 SHERBROOKE EST LIMITEE Avis est, par la présente, donné que « 530 SHERBROOKE EST LIMITEE ».incorporée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 17 octobre 1958.a transporté son siège social de Suite 720, 800 Place Victoria, Montréal, Québec, à Suite 2104, 800 Place Victoria, Montréal, Québec.Montréal, Québec, ce 21c jour de février, 1974.Le secrétaire-trésorier.56305-o Maurice Riel.330 SHERBROOKE EST LIMITEE Notice is hereby given that \"530 SHERBROOKE EST LIMITEE\", incorporated under Part I of the Companies Act bv letters patent dated October 17, 195S, has moved \"its head office from Suite 720, 800 Place Victoria, Montreal.Québec, to Suite 2104, 800 Place Victoria, Montreal, Québec.Montreal, Quebec, this 21st day of February, 1974.Maurice Riel, 56305-o Secret ary-Treasu rer.GERARD DORE INC.Avis est donné que la compagnie « GERARD DORE INC.», constituée en corporation par lettres patentes en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, en date du 24 août 1972, a établi son siège social au numéro 65 de la rue Fah-mount, dans les ville et district de Montréal.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté à Montréal, ce 8 février 1974.\\ Le président, 56306-o Gérard Doré.GERARD DORE INC.Notice is hereby given that \"GERARD DORE INC.\", incorporated by letters patent under the provisions of Part I of the Companies Act, on the 24th August 1972, has established its head office at number 65 Fairmount Street West, in the City and District of Montreal.From and after the date of this notice, the said office will be considered by the company as being its head office.Dated at Montreal, this February 8th, 1974.Gérard Doré, 56306-o President.REPRODUCTION A.R.T.INC.Avis est donné que la compagnie « REPRODUCTION A.R.T.INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 12 octobre 1973, et ayant son siège social à Montréal, district de Montréal, a établi son bureau à l'adresse suivante: 219 boulevard Roçkland, Montréal, district de Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Signé à Montréal, ce 19e jour de février 1974.(Sceau) Le président.56312-0 Jacques Trépanier.REPRODUCTION A.R.T.INC.Notice is hereby given that \"REPRODUCTION A.R.T.INC.\", company duly incorporated by letters patent on the 12th day of October 1973, and having its head office at Montreal, district of Montreal, has established its office at 219 Rockland Boulevard, Montreal, district of Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Signed at Montreal, this 19th day of February, 1974.(Seal) Jacques Trépanier, 56312-0 President. 1950 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9.197j.Vol.IPG, So.10 INSTITUT DE MEDIT \\ I KIN ET DE CINETIQUE CANADIEN DE MONTREAL INC.Avis est donné que la compagnie « INSTITUT DE MEDITATION ET DE CINETIQUE CANADIEN DE MONTREAL INC.», constituée en corporation sous la première partie de la Loi des compagnies du Québec en date du 3 juillet 1972, et ayant son siège social dans la ville de Montréal, a établi son bureau au 2.900 Est, rue Bélanger.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 7c jour de février 1974.Le secretaire, 56307-o Raymond Janelle.INSTITUT DE MEDITATION ET DE CINETIQUE CANADIEN DE MONTREAL INC.Notice is hereby given that '\u2022INSTITUT DE MEDITATION ET DE CINETIQUE CANADIEN DE MONTREAL INC.», incorporated under Part I of the Québec Companies Act on July 3, 1972 and having its head office in the City of Montreal, has established its office at 2,900 Bélanger Street East.From the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 7th day of February 1974.Raymond Janelle, 56307 Secretary.KNOWLTON REALTY (QUEBEC) LTD.KNOWLTON REALTY (QUEBEC) LTD.Avis est donné que la compagnie « KNOWLTON REALTY (QUEBEC) LTD.», constituée en corporation par lettres patentes émises sous la première partie de la Loi des compagnies en date du 21e jour de décembre 1967, et ayant son siège social dans le district de Montréal a établi son bureau à 629, 3 Place Ville Marie.À compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 15e jour de février 1974.Le secrétaire.56308-o John A.Penh ale.Notice is given that \"KNOWLTON REALTY (QUEBEC) LTD.\".incorporated by letters patent issued under Part I of the Companies Act on the 21st day of December, 1967, and having its head office in the District of Montreal has established its office at 629 - 3 Place Ville Marie.From the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Dated in Montreal, this 15th day of February, 1974.John A.Penhale, 56308-o Secretary.PEJAY CONSTRUCTION INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie «PEJAY CONSTRUCTION INC.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes datées du 23 août 1971, a transféré son siège social du numéro 1387, avenue Allan, en les ville et district de Montréal, au numéro 7026.avenue Guelph, en les ville et district de Montréal, province de Québec.Montréal, ce 8e jour île juin 1972.Le président, 56310 Paul Orlan.SAROGEX INC.Avis est donné que la compagnie « SAROGEX INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 6 juillet 1973 et ayant son siège social dans la ville de Montréal, dans la province de Quél>ec, a établi son bureau au numéro 1055 de Salaberry, app.12, dans les cité et district dc Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 29e jour de janvier 1974.Le président.56314-0 Fouad Sayegh.PEJAY CONSTRUCTION INC.Notice is hereby given that \"PEJAY CONSTRUCTION INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated August 23rd, 1971, has moved its head office from 1387 Allan Avenue, in the City and District of Montreal, to 7026 Guelph Avenue, in the City and District of Montreal, Province of Québec.Montreal, this 8th day of June, 1972.Paul Orlan, 56310-0 President.SAROGEX INC.Notice is given, that \"SAROGEX INC.\", incorporated by letters patent dated July 6th, 1973 and having its head office in the city of Montreal, in the Province of Québec, has established its office at 1055 de Salaberry, Apt.12, in the city and district of Montreal.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its principal office.Given at Montreal, this 29th day of January, 1974.Fou ad Sayegh, 56314-0 President. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n\" 10 1951 MEDNICK METAL CO.LTD.La compagnie « MEDNICK METAL CO.LTD.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Rouyn, à Parc Industriel, Noranda.Le secrétaire, Gaston Pratte.56309-o 11027-57 RAYMOND POUPART INC.Avis est donné que la compagnie « RAYMOND POUPART INC.», constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu de la Loi des compagnies en date du 4e jour de juin 1954 et ayant son siège social dans la ville de Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 2259 est, rue Ontario, l'a transporté au numéro 2272 est, rue Ontario.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, le 20e jour de février 1974.Le président, 5631 l-o Fernand Poupart.MEDNICK METAL CO.LTD.Notice is given that \"MEDNICK METAL CO.LTD.\" has transferred its head office from Rouyn, to Parc Industriel, Noranda.Gaston Pratte.Secretary.56309 11027-57 RAYMOND POUPART INC.Notice is given that \"RAYMOND POUPART INC.\", incorporated under the Companies Act, by letters patent issued on June 4th, 1954, and having its head office in the City of Montreal, where its office was located until the present day at 2259.Ontario Street East, has transferred said office to 2272 Ontario Street East.From the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Dated at Montreal, this 20th day of February, 1974.Fernand Poupart, 56311 President.RIVERSIDE TAXI LIMITED La compagnie « RIVERSIDE TAXI LIMITED » donne avis qu'elle a transféré son siège social de Sainte-Anne-de-Bellevue à Dorval.Le secrétaire, Roy C.Amaron.56313 723127 RIVERSIDE TAXI LIMITED Notice is given that \"RIVERSIDE TAXI LIMITED\" has transferred its head office from Sainte-Anne-de-Bellevue to Dorval.Roy C.Amaron, Secretary.56313-0 723127 TRANSPORT SAMSON INC.Avis est donné que la compagnie « TRANSPORT SAMSON INC.», constituée en corporation par lettres patentes datées du 28 novembre 1973 a établi son siège social à 171 est St-Joseph, Lauzon, district de Québec.Le secrétaire, 56315-0 Raymond Samson.TRANSPORT SAMSON INC.Notice is given that \"TRANSPORT SAMSON LNC\", incorporated by letters patent dated November 28, 1973, has established its head office at 171 St.Joseph East, Lauzon, District of Québec.Raymond Samson, 56315 Secretary.CO-MATIC INC.La compagnie « CO-MATIC INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Sainte-Claire, au numéro 2366, rue Galvani, Sainte-Foy.La secrétaire, Mme Irène L.Côté.56322-0 3095-64 CO-MATIC INC.Notice is given that \"CO-MATIC INC.\" has moved its head office from Ste.Claire to 2366 Galvani Street, Ste.Foy.Mrs.Irène L.Côté, Secretary.56322 3095-64 AIRPORT DELICATESSEN INC.La compagnie « AIRPORT DELICATESSEN INC.» donne avis quelle a changé son siège social du numéro 11425, Côte de Liesse, Montréal, Québec, au numéro 5765, rue Caldwell, Côte St.Luc, Montréal, Québec.Montréal, le 12 février 1974.Le secrétaire.56351-o Henry Majerczyk.AIRPORT DELICATESSEN INC.Notice is given that \"AIRPORT DELICATESSEN INC.\" has transferred its head office from 11425, Côte de Liesse Road, Montreal, Québec, to 5765 Caldwell Street, Côte St.Luc, Québec.Montreal, February 12, 1974.Henry Majerczyk, 56351-o Secretary. 1952 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.WG, A'o.10 ASSOCIATION D'ENTRAIDE VILLE-MARIE INC.Avis est donné que la corporation « ASSOCIATION D'ENTRAIDE VILLE-MARIE INC.».constituée en corporation dans la province de Québec par lettres patentes en vertu dc la troisième partie de la Loi des compagnies en date du 7 juin 1973.et ayant son siège social dans la Ville de Montréal a établi son bureau au numéro 880 est, de la rue Roy.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la corporation comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 29e jour de novembre 1973.Le -président, 56323-0 Jean-Paul Ramsay.ASSOCIATION D'ENTRAIDE VILLE-MARK INC.Notice is given that \"ASSOCIATION D'ENTRAIDE Vn.LE-MARD3 INC.\", incorporated in the Province of Québec under Part III of the Companies Act by letters patent dated June 7.1973.and having its head office in the City of Montreal, has established its office at 880 Roy Street East.From the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as its head office.Given in Montreal, this 29th day of November, 1973.Jean-Paul Ramsay, 56323 President.RADIO LA SARRE INC.La compagnie « RADIO LA SARRE INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Montréal, au numéro 68, rue Gamble.Rouyn.Le secrétaire.Jean Monette.56353-0 4450-49 RADIO LA SARRE INC.Notice is given that \"RADIO LA SARRE INC.\" has transferred its head office from Montreal, to 68 Gamble Street, Rouyn.Jean Monette, Secretary.56353-o 4450-49 SERVICE DE BATTERIE FOURNIER INC.La compagnie « SERVICE DE BATTERIE FOURNIER INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 1059.boulevard Ste-Anne, Beauport, au numéro 2199.boulevard Hamel, Sainte-Foy.Le secrétaire.Gilbert Lord.56354-0 733382 LUMINAIRES CLARA LTEE Avis est donné que la compagnie « LUMINAIRES CLARA LTEE », constituée en corporation en vertu de la première partie de la Ixli des compagnies en date du 28 novembre 1973.et ayant son siège social dans la ville de St-Eustache.a établi son bureau au numéro 350, boulevard Sauvé.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Ville de St-Eustache, le 12 février 1974.Ijc président de la compagnie, 56359-0 Henri Chauhktte.SERVICE DE BATTERIE FOURNIER INC.Notice is given that \"SERVICE DE BATTERIE FOURNIER INC.\" has transferred its head office from 1059 Ste.Anne Boulevard, Beauport, to 2199 Hamel Boulevard, Sainte-Foy.Gilbert Lord.Secretary.56354-o 733382 LUMINAIRES CLARA LTEE Notice is given that \"LUMINAIRES CLARA LTEE\", incorporated under Part I of the Companies Act, on November 28, 1973, and having its head office in the town of St.Eustache, has established its office at 350 Sauvé Boulevard.From the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Town of St.Eustache, February 12, 1974.Henri Chaurettb, 56359 President of the Company.MOZART (SHERBROOKE) LIMITED MOZART (SIIERRROOKE) LIMITEE La compagnie « MOZART (SHERBROOKE) LIMITED-MOZART (SHERBROOKE) LIMITEE » donne avis qu'elle a transféré son siège social du numéro 200.rue Wellington nord.Sherbrooke, au numéro 6517, rue Saint-Hubert.Montréal.Le vice-président, Seymour Steinman.¦\"\"':tM< 462-38 MOZART (SHERBROOKE) LIMITED MOZART (SHERBROOKE) LIMITEE Notice is given that \"MOZART (SHERBROOKE) LIMITED \u2014 MOZART (SHERBROOKE) LIMITEE\" has transferred its head office from 200 Wellington Street North, Sherbrooke, to 6517 St.Hubert Street Montreal.Seymour Steinman, Vice-president.56387-0 462-38 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, h° 10 1953 BORDELEAU & ASSOCIES INC.Avis est donne que la compagnie « BORDELEAU & ASSOCIES INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 9 janvier 1974 et ayant son siège social à Ville Saint-Laurent a établi son bureau au 1145 rue Guertin.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 14e jour de février 1974.La secrétaire, 56324-0 Louise La vigne Bordeleau.BORDELEAU & ASSOCIATES INC.Notice is hereby given that \"BORDELEAU & ASSOCIATES INC.\", company, incorporated by letters patent on the 9th day of January 1974, and having its head office in the City of Saint-Laurent, has established its office at No.1145 Guertin Street.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 14th day of February, 1974.Louise La vigne Bordeleau, 56324-0 Secretary.ATELIER DE DEBOSSFLAGE SANTERRE INC.Avis est donné que la compagnie « ATELIER DE DEBOSSELAGE SANTERRE INC.».constituée en corporation sous la première partie de la Loi des compagnies, par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives du Québec en date du 1er octobre 1973, a établi son bureau au numéro 173 de la rue Vignola, à Chutes-aux-Outardes.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Baie-Comeau, ce 24e jour de janvier, 1974.Le président.Émii.ien Santerre.56340-o 73-4357 R.GAVSIE & ASSOCIATES INC.La compagnie « R.GAVSIE & ASSOCIATES INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 1035, rue Beaumont au numéro 666 Sherbrooke Ouest, dans les ville et district de Montréal.La secrétaire.Susan Gavsie.5634 l-o 2692-70 ATELIER DE DEBOSSELAGE SANTERRE INC.Notice is hereby given that the company \"ATELIER DE DEBOSSELAGE SANTERRE INC.\", incorporated under Part I, of the Companies at by letters patents, bearing date the 1st day of October, 1973 issued hy the department of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of Québec has established its head office at number 173, Vignola Street, in the municipality of Chutes-aux-Outardes.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its bead office.Dated at Baie-Comeau, this 24th day of January 1974.Émilien Santerre, President.56340-o 73-4357 R.GAVSIE & ASSOCIATES INC.Notice is given that \"R.GAVSD3 & ASSOCIATES INC.\" has transferred its head office from 1035 Beaumont Street to 666 Sherbrooke Street West, Suite 1508 in the City and District of Montreal.Susan Gavsie, Secretary.56341-o 2692-70 LALLOUZ LUMBER COMPANY LTD.La compagnie « LALLOUZ LUMBER COMPANY LTD.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 2100, rue Drummond au numéro 5082, rue Glencairn dans la ville et district de Montréal.La secrétaire, Vivian Lallouz.56342-q 4021-70 LALLOUZ LUMBER COMPANY LTD.Notice is given that \"LALLOUZ LUMBER COMPANY LTD.\" has transferred its head office from 2100 Drummond Street to 5082 Glencairn in the City and District of Montreal.Vivian Lallouz, Secretary.56342-0 4021-70 LES IMMEUBLES GBH LIMITEE La compagnie « LES IMMEUBLES GBH LIMITEE » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 1440, rue Ste-Catherine ouest, Montréal, au numéro 480, boulevard Laurier, Mont Saint-Hilaire.Le secrétaire, Robert Chevrier.56352-0 4113-66 LES IMMEUBLES GBH LIMITEE Notice is given that \"LES IMMEUBLES GBH LIMITEE » has transferred its head office from 1440 St.Catherine Street West, Montreal, to 480 Laurier Boulevard, Mont Saint-Hilaire.Robert Chevrier, Secretary.56352-o 4113-66 1954 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 GROUPEX DISTRIBUTION INC.La compagnie -GROUPEX DISTRIBUTION INC.> donne avis qu'elle a changé son siège social de Laval, au numéro 7700, 6e Avenue, Rivière-des-Prai-ries.Le secrétaire, Emile Cousineau.56379-0 4464-68 GROUPEX DISTRIBUTION INC.Notice is given that \"GROUPEX DISTRIBUTION INC.\" has transferred its head office from Laval, to 7700 - 6th Avenue, Rivière-des-Prairies.Emile Cousineau, Secretary.56379 4464-68 LUCIEN BENOIT CONSTRUCTION LTEE La compagnie « LUCD3N BENOIT CONSTRUCTION LTEE » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 72.rue Parissi, Duvcrnay, Laval, au numéro 1019, rue De Nogent, Boucherville.Le secrétaire-trésorier, Fernand Bellemare.56380-o 14147-62 DESCHENES & FILS, LIMITEE La compagnie ' DESCHENES & FILS, LIMITEE » donne avis qu'elle a changé son siège social de Montréal-Est, au numéro 8335, boulevard St-Michel, Montréal.Le secrétaire, Jean Bertrand.56381-o 239-36 B.K.JOHL INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « B.K.JOHL INC.», constituée en corporation par lettres patentes datées du 15 mars 1946, et ayant son siège social en la ville Saint-Laurent, où son bureau était situé jusqu'à aujourd'hui au numéro 1200, boulevard Jules Poitras, a transféré ledit bureau au numéro 3500.chemin de la Côte Vertu, ville Saint-Laurent, Québec.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Fait à Montréal, ce 15e jour de juillet 1972.(Sceau Le président.Lester R.Johnsen.56382 2694-46 BERNARD J.VIAU INC.Avis est donné que la compagnie « BERNARD J.VIAU INC.», constituée en corporation par lettres patentes en vertu de la première partie de la Loi des compagnies le 1er novembre 1973 et ayant son siège social dans la municipalité de Ste-Adèle, où elle avait son bureau situé jusqu'à aujourd'hui au 381, rue Morin, l'a transporté au 16 Place de Ronchamp, à Ste-Adèle.comté et district de Terrebonne.P.Que.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Ste-Adèle, ce 21 décembre 1973.(Sceau) La secrétaire.Monique Meilleur-Viau.56388-0 738608 LUCIEN BENOIT CONSTRUCTION LTEE Notice is given that \"LUCIEN BENOIT CONSTRUCTION LTEE\" has transferred its head office from 72 Parissi Street, Duvernay, Laval, to 1019 De Nogent Street, Boucherville.Fernand Bellemare, Secretary-Treasurer.56380 14147-62 DESCHENES & FILS, LIMITEE Notice is given that \"DESCHENES & FILS, LIMITEE\" has transferred its head office from Montreal-East, to 8335 St.Michel Boulevard, Montreal.Jean Bertrand, Secretary.56381 239-36 B.K.JOHL INC.Notice is hereby given that \"B.K.JOHL INC.\", incorporated by letters patent on March 15, 1946, and having its head office in the City of St.Laurent, where its office was situated up to todav at 1200 Jules Poitras Blvd., has moved it to 3500 Côte Vertu Road, City of St.Laurent, Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 15th day of July, 1972.(Seal) Lester R.Johnsen, President.56382-o 2694-46 BERNARD J.VIAU INC.Notice is given that \"BERNARD J.VIAU INC.\", incorporated by letters patent under Part I of the Companies Act on November 1, 1973, and having its head office in the Municipality of Ste.Adèle, where its office was located until the present day at 381 Morin Street, has transferred said office to 16 Place de Ron-champ, in Ste.Adèle, County and District of Terrebonne, P.Que.From the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given in Ste.Adèle, this December 21, 1973.(Seal) Monique Meilleur-Viau, Secretary.56388 738608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106- année, n° 10 1955 LORIDA (QUEBEC) INC.La compagnie « LORIDA (QUEBEC) INC.» donne avis qu'elle a transféré son siège social du numéro 1, Place Ville Marie, suite 3635, Montréal, au numéro 1015, rue Edward, Laval.La secrétaire, Paula Barbarush.56384 627-70 MAINTENANCE INGETEC INC.La compagnie « MAINTENANCE INGETEC INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 1395, rue Fleury est, Montréal, au numéro 3461, boulevard Gouin est, suite 510, Montréal-Nord.Le secrétaire, Jean-Pierre Riel.56385-o 734732 METALINE ENTERPRISES INC.La compagnie « METALINE ENTERPRISES INC.* donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 2251, chemin St-François, Dorval 740, au numéro 388, rue St-Jacques, Suite 700, Montréal.Le secrétaire, Odilon Lanteigne.56386-0 715493 K.L.K.INC.La compagnie « K.L.K.INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 2000, boulevard Labelle, Laval, au numéro 600, Curé Boivin, Sainte-Thérèse-Ouest.Le secrétaire-trésorier, Serge Desrochers.56403-q 5540-69 LORIDA (QUEBEC) INC.Notice is given that \"LORIDA (QUEBEC; INC.\" has transferred its head office from 1 Place Ville Marie, Suite 3635, Montreal, to 1015 Edward Street, Laval.Paula Barbarush, Secretary.56384-o 627-70 MAINTENANCE INGETEC INC.Notice is given that \"MAINTENANCE INGETEC INC.\" has transferred its head office from 1395 Fleury Street East, Montreal, to 3461 Gouin Boulevard East, Suite 510, Montreal-North.Jean-Pierre Riel, Secretary.56385 734732 METALINE ENTERPRISES INC.Notice is given that \"METALINE ENTERPRISES INC.\" has transferred its head office from 2251 St.François Road, Dorval 740, to 388 St.James Street, Suite 700, Montreal.Odilon Lanteigne, Secretary.56386 715493 K.L.K.INC.Notice is given that \"K.L.K.INC.\" has transferred its head office from 2000 Labelle Boulevard, Laval, to 600 Curé Boivin, Ste.Thérèse-West.56403 Serge Desrochers, Secretary-Treasurer.5540-69 Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Révocation de dissolution Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, en vertu du paragraphe a de l'article 5/ de la Loi des renseignements sur les compagnies, qu'il a jugé à propos de faire droit à la demande d'intéressés faite dans les délais légaux à l'effet de révoquer la dissolution de Revocation of dissolution The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice, that pursuant to paragraph a of section 5/ of the Companies Information Act, he deemed it advisable to grant the petition of the interested parties made within the legal time limit, praying to revoke the dissolution of Nom de la compagnie Name of the Company\tDissolution Date\tGazette officielle No Official Gazelle No.CLUB BELLE NATURE INC.\t03 11 1973\t\u202214 en vertu de ladite loi et qu'il révoque ta dissolution de ladite compagnie.En conséquence, ladite compagnie est censée n'avoir jamais été dissoute en vertu de ladite loi, sans préjudice aux droits acquis par toute personne entre la dissolution et la révocation.56278-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.pursuant to the said Act and that he revokes the dissolution of the said company.Consequently, the said company, is considered as having never been dissolved under the said Act, without prejudice to the rights acquired by any person between the dissolution and the revocation.Pierre Desjardins.56278-0 Director of the Companies Service. 1956 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.March 9.1974.Vol.106.No.10 Changement de nom \u2014 Loi du Change of name \u2014 Act Demandes Applications George Hector Boynton Brosseau Avis est par les présentes donné que George Hector Boynton Brosseau, superviseur, domicilié au 175 boul.DeGuire, app.1402, dans les ville et district de Mont-tréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de George Hector Boynton et changeant le nom de son épouse, Dame Christine Anne Brosseau, domiciliée à l'adresse susmentionnée en celui de Dame Christine Anne Boynton.Montréal, ce 13c jour de février, 1974.Les avocats des requérantes.Duquet, Mackaï, Weldon, 56239-9-2-0 Bronstetter & Thivierge.George Hector Boynton Brosseau Notice is given that George Hector Boynton Brosseau, supervisor, domiciled at 175 DeGuire Blvd., Apt.1402, in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the granting of an order changing his name to that of George Hector Boynton, and changing the name of his wife Dame Christine Anne Brosseau, domiciled at the same address to that of Dame Christine Anne Boynton.Montreal, this 13th day of February, 1974.Duquet, Mackay.Weldon, Bronstetter & Thivierge, 56239-9-2-0 Attorneys for Applicants.George Kenneth Boynton Brosseau Avis est par les présentes donné que George Kenneth Boynton Brosseau, opérateur, domicilié au 2441 Grand Trunk Street, dans les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Kenneth Frederick Boynton et changeant le nom de son épouse, Dame Rita Alexina Brosseau domiciliée à l'adresse susmentionnée en celui de Rita Alexina Boynton.Montréal, ce 13e jour dc février, 1974.Les avocats des requérantes, Duquet, Mackay, Weldon, 56240-9-2-o Bronstetter & Thivierge.Marie Anna Adélaïde Lalonde Avis est par la présente donné que Marie Anna Adélaïde Lalonde.ménagère, résidante et domiciliée au 1053, rue St-.Iean, à Chambly, district dc Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil d'adopter officiellement le nom de Germaine Fortier.Longueuil, le 23 janvier 1974.Le* procureurs de la requérante.Pilon.Ferrari, 56194-9-2-0 Braconnier.Larivière.Marie Régina Yvette Violette Taylor W in l'uni Avis est donné par les présentes que Marie Régina Yvette Violette Taylor Winford, ménagère, de 2259 avenue Madison, Montréal, entend présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil demandant le changement de son nom à Mary Jo Holland Winford, conformément aux dispositions de la Loi du changement du nom.Montréal, le 7 janvier 1974.Le procureur de la requérante.56195-9-2-0 Me Warren Baer.George Kenneth Boynton Brosseau Notice is hereby given that George Kenneth Boynton Brosseau, operator, domiciled at 2441 Grand Trunk Street in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the granting of an order changing his name to that of Kenneth Frederick Boynton, and changing the name of his wife, Dame Rita Alexina Brosseau domiciled at the same address, to that of Rita Alexina Boynton.Montreal, this 13th day of February, 1974.Duquet, Mackay, Weldon, Bronstetter & Thivierge, 56240-9-2-o Attorneys for Applicants.Marie Anna Adélaïde Lalonde Notice is hereby given that Marie Anna Adélaïde Lalonde, residing at 1053, St-Jean, in Chambly, District of Montreal, will make application to the Lieutenant-Governor in council to bave her name changed to Germaine Fortier.Longueuil, this January 23, 1974.Pilon, Ferrari.Braconnier, Larivière.56194-9-2-0 Attorneys for Pétitionner.Marie Régina Yvette Violette Taylor Winford Notice is hereby given that Marie Régina Yvette Violette Taylor Winford.housewife, domiciled at 2259 Madison Avenue.Montreal, intends to present a petition to the Lieutenant-Governor in Council requesting the change of her name to Mary Jo Holland Winford, pursuant to the provisions of the Change of Name Act.Montreal, January 7th, 1974.M un.Warren Baer, 56195-9-2-q Attorney for Petitioner. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 1957 Robert Roy Avis est par les présentes donné que Robert Roy, résidant et domicilié au 87 A, Des Laurentides, Ville de Laval, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, pour obtenir un décret changeant son nom de Robert Roy en celui de Robert Frederic de Monsroy.Montréal, ce 14 février 1974.Les procureurs du requérant.Mes Shadley, 56196-9-2-0 Melançon & Ass., avocats.Robert Roy Take notice that Robert Roy, residing and domiciled at 87 A, Des Laurentides Blvd., City of Laval, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from Robert Roy to Robert Frederic de Monsroy.Montreal, February 14, 1974.Mes Shadlet, Melançon & Ass., lawyers, 56196-9-2-0 Attorneys for the Petitioner.Lise Martel Avis est par les présentes donné que.Lise Martel, domiciliée au 366, rue Gélinas, app.2, Cap-de-la-Madeleine, présentera une requête au ministre de la justice, pour changer son nom en celui de Lise St-Pierre.Ce changement n'affectera aucune autre personne que la requérante elle-même.Trois-Rivières, le 2 mars 1974.Les procureurs de la requérante, 56241-9-2-0 Martin & Blais, notaires.Lise Martel Notice is hereby given that Lise Martel domiciled at 366 Gélinas, Appt.2, Cap-de-la-Madeleine, will present a petition to the Minister of Justice in order to change her name to that of Lise St-Pierre.This change will not affect any person else than the applicant.Trois-Rivières, March 2, 1974.Martin & Blais, Notaries, 56241-9-2-o Attorneys for the Applicants.Corinne Jeanne Ashton Corinne Jeanne Ashton, généralement connue sous le nom de Corinne Jeanne Samson, serveuse, de la ville de Candiac, district de Montréal, où elle est domiciliée et demeurant au numéro 55, avenue Hermes.Avis est donné par les présentes que Corinne Jeanne Ashton s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin de changer son nom de Corinne Jeanne Ashton en celui de Corinne Jeanne Samson.Le 7 février 1974.Le procureur de la requérante.56261-9-2 Me Robert G.Wolfe, avocat.Corinne Jeanne Ashton Corinne Jeanne Ashton, publicly known as Corinne Jeanne Samson, waitress, of the Town of Candiac, District of Montreal, therein domiciled and residing at 55 Hermes Avenue.Notice is hereby given that Corinne Jeanne Ashton will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have her name changed from Corinne Jeanne Ashton to Corinne Jeanne Samson.February 7th, 1974.Mtre Robert G.Wolfe, advocate, 56261-9-2-0 Attorney for the Petitioner.Mark Brian Epstein Avis est par les présentes donné que Mark Brian Epstein, résidant et domicilié au 5717 Wentworth, Côte St-Luc, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, pour un décret changeant son nom de Mark Brian Epstein à celui de Mark Brian Epstein Singer.Montréal, ce 19 février 1974.Les avocats, 56264-9-2-0 Mes Rothman & Rubin.Mark Brian Epstein Notice is hereby given that Mark Brian Epstein, residing and domiciled at 5717 Wentworth, Côte St.Luc, district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from Mark Brian Epstein to Mark Brian Epstein Singer.Montreal, February the 19th, 1974.Mes Rothman & Rubin, 56264-9-2-0 Lawyers.Fikin Leon Sabbag Avis est donné que Fikin Léon Sabbag, commerçant, demeurant au 70 boul.Crépeau, ville St-Laurent, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Viken Léon Sabbaghian.Montréal, le 20 février 1974.Les procureurs du requérant, 56265-9-2-0 Awada, Gareau & Sumbulian.Fikin Leon Sabbag Notice is hereby given that Fikin Léon Sabbag, Businessman, residing at 70 Crépeau Blvd., Ville St.Laurent, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the adoption of an order changing his name to that of Viken Léon Sabbaghian.Montreal, February 20, 1974.Awada, Gareau & Sumbulian, 56265-9-2-0 Attorneys for Petitioner. 1958 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 9.1974.Vol.106.No.10 J h I in- Cappel Avis est par la présente donné que Julius Cappel.vendeur, résidant et domicilié au 400 avenue I.ans-downe, ville de Wcstmount, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, un décret changeant son nom en celui dc Julius Cappel!, duquel changement bénéficiera aussi son épouse, Mildred Cappel, domiciliée à l'adresse ci-haut mentionnée.Montréal.22 février 1974.Les procureurs du requérant, Greenblatt, Godinsky, Resin 56262-9-2-q & Uditsky.Julius Cappel Notice is hereby given that Julius Cappel, salesman, residing and domiciled at 400 Lansdowne Avenue, Westmount, Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec, for an order changing his name to Julius Cappell, which change will also benefit his wife, Mildred Cappel, residing and domiciled at the address mentioned above.Montreal, February 22nd, 1974.Greenblatt, Godinsky, Resin & Uditsky, 56262-9-2-o Attorneys for Applicant.Arnold Gelbartowicz Avis est par les présentes donné que Arnold Gelbartowicz, demeurant au numéro 7513, chemin Euclide, Cité de Côte-Saint-Luc, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin de changer son nom de Arnold Gelbartowicz en celui de Arnold Gilbert.Le 22 février 1974.L'avocat, 7053, chemin Côte-Saint-Luc, June Gagnon.Côte-Saint-Luc, P.Q.56279-10-2 Arnold Gelbartowicz Notice is given that Arnold Gelbartowicz, residing at 7513 Euclid Road, City of Côte St.Luc, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to change his name from Arnold Gelbartowicz to Arnold Gilbert.February 22, 1974.June Gagnon, 7053 Côte- St.Luc Road.Lawyer.Côte St.Luc, P.Q.56279-10-2-o Nathan Belinsky Avis est par les présentes donné que Nathan Belinsky, courtier d'assurance, demeurant au No 6211 Côte St-Luc, app.306, Hampstead, P.Q.s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant ses nom et prénom en ceux de « James N.Bellin ».Montréal, ce 5 février 1974.Le procureur du requérant, 56327-10-2-o Guy Lacoste, notaire.Nathan Belinsky Notice is hereby given that Nathan Belinsky, insurance broker, residing at No.6211, Côte St.Luc, Apartment 306.Hampstead, P.Q.will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his given name and surname to James N.Bellin.Montreal, February 5, 1974.Guy Lacoste, Notary, 56327-10-2 Attorney for the Petitioner.Marie-Hélenc Kaymonde Carole Ferron Avis est donné que Mademoiselle Marie-Hélène Raymonde Carole Ferron.serveuse-hôtesse, demeurant à Longueuil, au numéro 99 rue Montarville, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret lui permettant de changer son nom de Marie-Hélène Raymonde Carole Ferron en celui dc Francine Devost.Longueuil, le 4 février 1974.ht notaire de la requérante, 56358-10-2-o Andre Chabot.Jacob Brodmann Avis est par les présentes donné que Jacob Brodmann, joaillier, résidant et domicilié au 4875 Dufferin Road, Montréal, province de Québec, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec un décret changeant son nom en celui dc Jacques Brodman.Montreal, le 21 février, 1974.Les procureurs du requérant, 56365-10-2-o Geoffrion & Prud'Homme.Marie-Hélène Raymonde Carole Ferron Notice is hereby given that Miss Marie-Hélène Raymonde Carole Ferron, hostess, living at Longueuil, 99 Montarville Street, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for permission to change her name from Marie-Hélène Raymonde Carole Ferron to Fran-cine Devost.Longueuil, February 4, 1974.André Chabot, 56358-10-2-o Notary for the Applicant.Jacob Brodmann Notice is hereby given that Jacob Brodmann, jeweller, residing and domiciled at 4875 Dufferin Road, Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing his name to that of Jacques Brodman.Montreal, February 21, 1974.Geoffrion & Prud'Homme, 56365-10-2 Attorneys for Applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 mars 1974.106' année, n° 10 1959 Joseph Mastaï Jean Luc Coutu Avis est par les présentes, donné selon l'article 5, Loi du changement de nom, que Joseph Mastaï Jean Luc Coutu, officier d'immigration, demeurant et domicilié au No 1160 rue Alexandre De Sève, apt.2, en les cité et district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption d'un décret changeant son nom à Joseph Mastaï Jean Luc Coutu de Lavaltrie.Le changement de son nom bénéficiera aussi à sa femme, de la même adresse.Montréal, le 20 février 1974.Les -procureurs du requérant, 56263-9-2-0 Bélanger & Blais.Joseph Mastaï Jean Luc Coutu Notice is hereby given pursuant to section 5 of the Change of Name Act that Joseph Mastaï Jean Luc Coutu, immigration officer, residing and domiciled at 1160 Alexandre de Sève, No.2, in the City and district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for the adoption of an order changing his name to Joseph Mastaï Jean Luc Coutu de Lavaltrie.The change of name shall benefit his wife of same address.Montreal, February 20, 1974.Bélanger & Blais, 56263-9-2-0 Attorneys for the Applicant.Gerald Altrovitch Avis est donné par les présentes que Gerald Altrovitch, pharmacien, résidant au numéro 787, 100e Avenue, Chomedey, Laval, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Gerald Altrows; ledit changement de nom devant aussi s'appliquer à son épouse, née Aileen (également connue sous le nom de Eileen) Lerner, et à ses enfants Earl Ryan, Michael Richard, Eve, Dale et Kim, tous demeurant à la même adresse.Montréal, le 14 février, 1974.Le procureur du requérant, 56364-10-2-o Lawrence Capelovitch.Gerald Altrovitch Notice is hereby given that Gerald Altrovitch, pharmacist, residing at 787, 100th Avenue, Chomedey, Laval, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Gerald Altrows; said change of name shall also benefit his wife, née Aileen (also known Eileen) Lerner, and his children, Earl Ryan, Michael Richard, Eve, Dale and Kim, all of the same address.Montreal, February 14th, 1974.Lawrence Capelovitch, 56364-10-2-o Attorney for Petitioner.Léon Vahan Melemetdjian Avis est donné par les présentes que Léon Vahan Melemetdjian, chirurgien-dentiste, résidant au 8325, L'Acadie, Suite 403, à Montréal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Léon Vahan Lemian, ledit nom servant à toutes fins que de droit.Montréal, le 21 février.1974.Les procureurs du requérant, Valiquette, Blouin & 56366-10-2-o Kochenburger.Léon Vahan Melemetdjian Notice is hereby given that, Léon Vahan Melemetdjian, dental surgeon, residing at 8325 L'Acadie, Suite 403, in Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of Léon Vahan Lemian, said name to be used for all legal purposes.Montreal, February 21, 1974.Valiquette, Blouin & Kochenburger, 56366-10-2 Attorneys for applicant.Marie Berthe Alice Lebel Avis est donné que Marie Berthe Alice Lebel, ménagère, épouse de Fernand Lachapelle, résidant et domiciliée au 8075, rue Lafontaine, app.2, Montréal, district de Montréal, s'adressera au ministre de la justice de la province de Québec, en vue d'obtenir du lieutenant-gouverneur en conseil un décret changeant son nom en celui de Lucienne Lebel.Montréal, ce 1er mars 1974.Les procureurs de la requérante, Johanne Gagnon Trudel, Hargreaves, Monette, 56427-lO-2-o Trudfl & Leduc.Marie Berthe Alice Lebel Notice is hereby given that Marie Berthe Alice Lebel.housewife, wife of Fernand Lachapelle, residing and domiciled at 8075 Lafontaine Street, Apt.2, Montreal, district of Montreal, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec, for a decree of the Lieutenant-Governor in Council, changing her name to Lucienne Lebel.Montreal, March 1st, 1974.Johanne Gagnon Trudel, Hargreaves, Monette, Trudel & Leduc, 56427-10-2-o Attorneys for the Applicant. 1960 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 9.1974.Vol.106.No.10 Enny de Jongh Swemer Avis est donné que dame Enny de Jongh Swemer, domiciliée au 1808 rue Sherbrooke, Montréal, présentera au ministre de la justice une requête lui permettant de changer son nom en celui de Dyanne Brettshaw.56435-10-2-o Enny de Jongh Swemer.Enny de Jongh Swemer Notice is hereby given that Mrs.Enny de Jongh Swemer, domiciled at 1808 Sherbrooke Street, Montreal, will apply to the Minister of Justice for an order changing her name to Dyannc Brettshaw.56435-10-2 Enny de Jongh Swemer.Compagnies étrangères Agent Extra-Provincial Companies Agent JAMES B.CARTER, LIMITED Avis est donné qu'en vertu d'une nouvelle procuration en date du 3 décembre 1973, dont copie a été remise au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, monsieur Brian Earl Johnston, de Westmount, a été nommé en remplacement de monsieur Angus R.McLoed à titre d'agent principal dans la province de « JAMES B.CARTER, LIMITED », une compagnie étrangère dûment autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies étrangères.Avis est également donné qu'en vertu de la nouvelle procuration ci-dessus mentionnée, le siège social dc ladite compagnie est établi au numéro 2225, rue La-pierre, LaSalle 660, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives.Albert Jessop.56373 PA: 32-62 JAMES B.CARTER, LIMITED Notice is given that, by new power of attorney dated December 3rd, 1973, a copy of which was sent to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, Mr.Brian Earl Johnston, of Westmount, was appointed to replace Mr.Angus R.McLoed as chief agent in the Province of \"JAMES B.CARTER.LIMITED\", an Extra-Provincial Company duly authorized to carry on business in the Province of Québec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act.Notice is also given that pursuant to the above-mentioned new power of attorney, the head office of the said company is established at 2225 Lapierre Street, LaSalle 660, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.56373-o PA: 32-62 Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies License MORIN EQUIPMENT (1973) LTD.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis que le 30e jour de janvier 19/4, il a accordé un nouveau permis à la compagnie « P.LAWSON TRAVEL (ALBERTA) LTD.», l'autorisant à exercer son commerce dans la province sous son nouveau nom de « MORIN EQUIPMENT (1973) LTD.», conformément aux dispositions de la Loi des compagnies étrangères, Statuts refondus, 1964, chapitre 282.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur Cyprien Picard, 2903, Vincenncs, Sainte-Foy.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province est établi au numéro 2075, Branly, Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives.,\u201e__\u201e Albert Jessop.56272 PA: 17-63 MORIN EQUIPMENT (1973) LTD.Notice is given that, on 30th day of January, 1974, a new license was granted by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to \"P.LAWSON TRAVEL (ALBERTA) LTD.\", authorizing it to carry on business in the Province under its new name of \"MORIN EQUIPMENT (1973) LTD.\", pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes, 1964, chapter 282.The chief agent for the purpose of receiving services in proceeding against the said company, is Mr.Cyprien Picard, 2903 Vinccnnes, Sainte-Foy.The principal office of the said company in the Province is at 2075 Branly, Sainte-Foy, judicial District of Québec.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.56272-0 PA: 17-63 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106- année, n° 10 1961 Avis divers Succession Miles Gilbert Walker Avis est par les présentes donné qu*en vertu d'un acte d'acceptation sous bénéfice d'inventaire reçu devant Malcolm MacLennan, notaire.No.276, rue St.Jacques ouest, Montréal, le 17 octobre, 1973, et enregistré au bureau d'enregistrement de Montréal, le 25 octobre, 1973, sous le No 2470007, Harold E.Walker, de la cité de Montréal, résidant à No 4507 Avenue Mayfair, a accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de Miles Gilbert Walker de son vivant de la cité de Côte St.Luc, décédé le 1 Mars, 1972.Le notaire, 56330-o Malcolm MacLennan.HOPITAL SAINT-JOSEPH ARTISAN Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a déclaré la corporation « HOPITAL SAINT-JOSEPH ARTISAN », constituée en corporation par lettres patentes émises le 24 novembre 1960, en vertu de l'article 25 de la Loi constituant en corporation les Oblates Franciscaines de Saint-Joseph, chapitre 158 des lois de 1956-1957, dissoute en vertu de l'article 25 précité, cette dissolution devant prendre effet à compter du soixantième jour de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.56372-0 HOP: 14885-60 ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE DE ST-FERDINAND INC.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour dc janvier 1974, constituant en corporation sans capital-actions, sous le nom de « ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE DE ST-FERDINAND INC.», les membres actuels de « CLUB DE CHASSE ET PECHE DE ST-FERDINAND\", déjà constituée en corporation le ou vers le 7 février 1958, en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus.1964, chapitre 298).Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $50,000.Le siège social de la nouvelle corporation est à Saint-Ferdinand, district judiciaire de Mégantic.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.56272-o 740089 Miscellaneous Notices Estate of Miles Gilbert Walker Notice is hereby given that by Deed of Acceptance Under Benefit of Inventory, passed before M.MacLennan.N.P.No.276 St.James Street West, Montreal, on the 17th day of October, 1973, registered in the Montreal Registry Office on the 25th day of October, 1973, under No.2470007, Harold E.Walker, of the City of Montreal, residing and domiciled at No.4507 Mayfair Avenue, has accepted under benefit of inventory the Estate of Miles Gilbert Walker, in his lifetime of the City of Côte St.Luc, who died on the 1st day of March, 1972.Malcolm MacLennan, 56330-o Notary.HOPITAL SAINT-JOSEPH ARTISAN The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that he has declared \"HOPITAL SAINT-JOSEPH ARTISAN\", incorporated by letters patent issued on November 24, 1960, pursuant to section 25 of the Act to incorporate Les Oblates Franciscaines de Saint-Joseph, Chapter 158 of the Statutes of 1956-1957, dissolved pursuant to the aforementioned section 25, said dissolution to take effect from the sixtieth day following the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.56372 HOP: 14885-60 ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE DE ST-FERDINAND INC.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that under Part III of the Companies Act, he has issued letters patent, dated the 3rd dav of January, 1974, incorporating without share capital, under the name of \"ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE DE ST-FERDINAND INC.\", the present members of \"CLUB DE CHASSE ET PECHE DE ST-FERDINAND\", already incorporated on or about February 7, 1958, under the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 298).The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $50,000.The head office of the new corporation is located in St.Ferdinand, Judicial District of Mégantic.Pierre Desjardins, Director of the compagnies service.56272 740089 1962 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 9, 1974, Vol.106, No.10 Succession Louis Marchand Avis est donné que Monsieur Ferdinand Marchand, rentier, en sa qualité de tuteur à son fils mineur Luc Marchand, a accepté sous bénéfice d'inventaire, par acte signé devant Me Gérard Fradet, notaire à Drum-im méopold Moretti Q.L.8., dated August 4, 1966, under number C-6478 of his minutes and is described hereinabove by said land- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1971,, 106' année, n° 10 2017 par ledit arpenteur-goémétre en une description technique en date du 6 juillet 1971.Avec un droit de passage en commun dans les chemins privés pour communiquer dudit emplacement au chemin public.Taxes municipales: $17.33.Dame Irène Jacques, veuve de Louis Rrisebois.\u2014 Un emplacement situé en la municipalité du Dunany, comté d'Argenteuil, faisant partie du lot originaire numéro deux, lettre « B », dans le Troisième Rang (Ptie 2-B, Rg.III) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, division d'enregistrement d'Argenteuil; Ledil emplacement étant de forme irrégulière et bornée comme suit: vers le sud, par une partie dudit lot 2-B (étant un chemin), vers le nord, par le lac Bixley, vers le nord-ouest et l'est, par d'autres parties dudit lot 2-B, rang III; Mesurant cent vingt-cinq pieds et quatre-vingt-sept centièmes de pied (125.87') en front, dans sa ligne sud; cent quatre-vingt-huit pieds et cinquante-huit centièmes de pied (188.58') dans sa ligne nord-ouest; cinquante-quatre pieds et quarante-cinq centièmes de pied (54.45') dans sa ligne nord (le long du lac); cent vingt-deux pieds et quatre-vingt-cinq centièmes de pied (122.85') dans sa ligne est; contenant une superficie de onze mille sept cent soixante-quatre pieds carrés (11,764 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; Le coin nord-ouest de cet emplacement est situé à trois cent quarante pieds et seize centièmes de pied (340.16') vers le sud-est du lot No 3, et à quatre cent quatre-vingt-sept pieds et quatorze centièmes de pied (487.14') vers le nord-est du lot 2-A; Le coin sud-ouest est situé à trois cent quarante pieds et soixante-treize centièmes de pied (340.73') vers le sud-est du lot No 3, et à deux cent quatre-vingt-dix-huit pieds et quarante centièmes de pied (298.40') vers le nord-est du lot No 2-A, du Troisième Rang, dudit canton; Cet emplacement porte le numéro deux (No 2), sur un plan de subdivision projetée préparé par Leopold Moretti, a.c, en date du vingt et un mai, mil neuf cent soixante-quatre ; Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, y attachées.Avec droit de passage avec tous autres y ayant droit, dans les rues projetées communiquant audit emplacement, au lac et à la plage; avec un camp d'été dessus érigé.Taxes municipales: $98.64.Marie Rose St-Louis, épouse de Roland Simard, adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-50, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cinquante (50) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A » (1A-50 Rg.3).Taxes municipales: $17.33.Lionel Trottier, 1540 Crevier, St-Laurent\u2014Lot No 1B-34, rang 3.surveyor, in a technical description, dated July 6, 1971.Subject to a common right of way on the private roads leading from said emplacement to the public road.Municipal taxes: $17.33.Mrs.Irène Jacques, widow of Louis Brisebois.\u2014 An emplacement located in the Municipality of Dunany, County of Argenteuil, forming part of original lot number two, letter \"B\", in the Third Range (Pt 2-B, R.Ill) on the official plan and in the book of reference for the Township of Wentworth, Argenteuil Registration Division; Said emplacement being of irregular configuration and bounded as follows: towards the south by a part of said lot 2-B (being a road), towards the north by Lake Bixley, towards the northwest and the east by other parts of said lot 2-B, Range III; Measuring one hundred twenty-five and eighty-seven hundredths feet (125.87') in front, on its south line; one hundred eighty-eight and fifty-eight hundredths feet (188.58') on its northwest line; fifty-four and forty-five hundredths feet (54.45') on its north line (along the lake shore); one hundred twenty-two and eighty-five hundredths feet (122.85') on its east line; covering an area of eleven thousand seven hundred sixty-four square feet (11,764 sq.ft) English measure, more or less; The nprthwestern corner of said emplacement is located at a distance of three hundred forty and sixteen hundredths feet (340.16') to the southeast of lot No.3, and at a distance of four hundred eighty-seven and fourteen hundredths feet (487.14') to the northeast of lot 2-A; The southwestern corner is located at a distance of three hundred forty and seventy-three hundredths feet (340.73') to the southeast of lot No.3, and at two hundred ninety-eight and forty hundredths feet (298.40') to the northeast of lot No.2-A, in the Third Range of said Township; Said emplacement is known as number two (No.2), on a proposed subdivision plan prepared by Leopold Moretti, q.l.s., dated May twenty-first, one thousand nine hundred sixty-four; As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes, attaching thereto.Subject to a right of way with all others entitled thereto, in the proposed streets leading to the said emplacement, to the lake and to the beach; with a summer camp erected thereon.Municipal taxes: $98.64.Marie Rose St.Louis, wife of Roland Simard, unknown address.\u2014 Lot No.1A-50, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth in the County of Argenteuil, as being the lot number fifty (50) of the official subdivision of the original lot number one \"A\"; (1A-50 R.3).Municipal taxes: $17.33.Lionel Trottier, 1540 Crevier, St.Laurent.\u2014 Lot No.1B-34, Range 3. 2018 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-quatre (34) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B \u2022, rang 3.Taxes municipales: $33-73.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-15, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quinze (15) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A » (1A-15), rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc.; adresse inconnue Lot No 1A-16, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro seize de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-15, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quinze (15) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un \u2022 B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-17, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro dix-sept (17) dc la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B \", rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-19, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro dix-neuf (19) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-21, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth.dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt et un (21) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-22, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt- A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth in the County of Argenteuil as being the lot number thirty-four (34) of the official subdivision of the original lot numberone \"B\", Range 3.Municipal taxes: $33.73.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-15, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifteen (15) of the official subdivision of the original lot number one \"A\", (1A-15) Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-16, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number sixteen (16) of the official subdivision of the original lot number one \"A\", R.3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.IB-15.Range3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifteen (15) of the official subdivision of the original lot number one \"B\", R.3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-17, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number seventeen (17) of the official subdivision of the original lot number one \"B\", R.3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.IB-19, Range3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth.in the County of Argenteuil, as being the lot number nineteen (19) of the official subdivision of the original number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-21, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil.as being the lot number twenty-one (21) of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes : $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-22, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 2019 deux (22) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-9, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro neuf (9) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $41.93.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-11, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro onze (11) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B »,rang3.Taxesmunicipales:$27.Ï7.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-33, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-28, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.-\u2014 Lot No 1A-35, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-cinq de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-36, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-37, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Ar-gentuil, comme étant le lot numéro trente-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales : $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No !A-26,rang3.the lot number twenty-two (22) on the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes : $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-9, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number nine (9) of the official subdivision of the original lot number one \"B\", range ?.Municipal taxes: $41.93.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-11, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number eleven (11) of the official subdivision of the original lot number one 'B', range 3.Municipal taxes: $27.17.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-33.Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-three, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Ix>t No.1A-28.Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number twenty-eight of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-35, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil as being the lot number thirty-five of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-36.Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-six, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-37, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-seven of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-26, Range 3. 2020 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1911,, Vol.106, No.10 Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-39, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales : $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-23, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt-trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-40, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-27, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No lB-29,rang3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No lB-31,rang3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente et un de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No lB-32,rang3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number twenty-six of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-39, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-nine of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014Lot No.1A-23, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number twenty-three, of the official subdivision of the original lot number one \"A\" range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-40, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-27, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number twenty-seven, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-29, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number twenty-nine, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes : $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.lB-31,Range3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-one, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-32, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-two, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106- année, n° 10 2021 Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-53, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cinquante-trois, de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-56, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cinquante-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-57, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cinquante-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-59, rang 3.Un certain terrain connu et designé aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cinquante-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-60, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No lA-48,rang3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-47, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-46, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-53, Range 3.A certain piece of land known and designated on the of the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifty-three, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-56, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifty-six, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-57, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifty-seven, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-59, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifty-nine, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-60, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number sixty, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-48, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty-eight, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-47, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty-seven, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-46, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of 2022 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A», rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-61, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante et un de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A »,rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-62, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-64; 1B-46, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A » ; et le lot numéro quarante-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-47, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-48, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-huit de la subdrvision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-42, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre dc renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-41, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton dc Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante et un de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty-six, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-61, Range 3.A certain piece of land known arid designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number sixty-one of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-62, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number sixty-two, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-64; 1B-46, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil.as being the lot number sixty-four of the official subdivision of the original lot number one \"A\"; and lot number forty-six of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.¦\u2014 Lot No.1B-47, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty-seven, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-48, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty-eight, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-42, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty-two, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-41, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty-one, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 2974, 106- année, n° 10 2023 Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-49, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-50, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cinquante de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-40, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-39, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-38, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-52, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cinquante-deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-53, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cinquante-trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-70, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixan- Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-49, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty-nine, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-50, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifty, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-40, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-39.Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-nine, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-38, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-eight of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-52, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifty-two, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-53, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifty-three, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-70, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the 2024 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9.1974, Vol.106, No.10 tc-dix de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-77, rang 3.Un certain terrain connu et désigne aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-dix-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang S.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-69, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-68, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-78, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-dix-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-79, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-dix-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-80; 1B-67, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3 et le lot numéro soixante-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un «B», rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-64, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.lot number seventy, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-77, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth in the County of Argenteuil, as being the lot number seventy-seven, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-69, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth in the County of Argenteuil, as being the lot number sixty-nine, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-68, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth in the County of Argenteuil, as being the lot number sixty-eight, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-78, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth in the County of Argenteuil, as being the lot number seventy-eight, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.8b.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-79, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number seventy-nine, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-80; 1B-67, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number eighty of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3, and of lot number sixty-seven of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-64, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number sixty-four of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n\" 10 2025 Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-63, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livie de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comte d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-68, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-61, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre dc renvoi officiels du canton dc Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante et un de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-75, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-quinze de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-90, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-dix de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-92, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-douze de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-93, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-treize de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-94, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-63, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number sixty-three, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-68, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number sixty-eight, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-61, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number sixty-one, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-75, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number seventy-five, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-90, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-92, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety-two, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-93, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety-three, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-94, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of 2026 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 191 J,, Vol.106, No.10 comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-quatorze de la subdivision officielle du lot originaire numéro un «A», rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-95, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-quinze de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc.adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-98, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-dix-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-99, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-dix-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro un «A», rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-88, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton dc Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-100, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cent de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-101, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cent un de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-102, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cent deux de la subuivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety-four, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-95, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety-five, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-98, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety-eight, of the official subdivision' of the original lot number one \"A\", Rangée 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-99, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety-nine, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-88, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number eighty-eight, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-100, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number one hundred, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-101, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number one hundred one, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-102, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number one hundred two, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $9.13. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 2027 Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-86, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $17.33.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-84, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », Rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-82, 1B-86, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », et le lot numéro quatre-vingt-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $585.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-105, 1B-88, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cent-cinq de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A » et le lot numéro quatre-vingt-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-89, 1A-106, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro 1 « B », rang 3 et le lot numéro cent six de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-90, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-dix de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-91, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-onze de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-86, Range 3.A certain piece of land known and designated on tbc official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number eighty-six, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes : $17.33.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-84, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number eighty-four, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-82, 1B-86, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number eighty-two, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", and the lot number eighty-six of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-105; 1B-88, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number one hundred five, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", and of lot number eighty-eight of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot Nos.1B-89; 1A-106, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number eighty-nine of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3; and the lot number one hundred six of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-90, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-91, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety-one, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $9.13. 2028 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-85, 1A-81, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-cinq de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B » et le lot numéro quatre-vingt-un de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », tous deux dans le rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-93, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant lt lot numéro quatre-vingt-treize de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », Rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-94, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil.comme étant le lot numéro quatre-vingt-quatorze de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-95, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-quinze de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-96, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-seize de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-97, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-dix-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-98, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth.dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-dix-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $9.13.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-78, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-85; 1A-81, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number eighty-five of the official subdivision of the original lot number one \"B\", and of lot number eighty-one of the official subdivision of the original lot number one \"A\", all in Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-93, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety-three, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-94, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety-four, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-95, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety-five, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-96, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety-six, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-97, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety-seven, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-98, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number ninety-eight, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $9.13.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-78, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 2029 comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-dix-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: S5.85.Municipalité du canton de Gore Hogan Bousquet, 11163, Pie IX, Montréal, Que.\u2014 Un emplacement vacant situé dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant composé des lots numéros cent vingt-six et cent vingt-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un, lettre « A », dans le Deuxième Rang (l-A-126 & 127, Rg II) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil; Mesurant ledit emplacement, cent pieds (100') de largeur, dans ses lignes nord-ouest et sud-est, sur une profondeur de cent pieds (100'; dans ses lignes sud-ouest et nord-est, formant une superficie totale dc dix mille pieds carres (10,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins.Taxes municipales: $26.20.Yvon Boudreau, 6976, Querbes, Montréal, Que.\u2014 Un emplacement vacant situé dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme faisant partie du lot originaire numéro un, lettre « A », dans le Troisième Rang (Pties-l-A, Rg III), aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil; Borné comme suit: au sud-ouest, par une rue projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant partie dudit lot 1A, Rang LU (l-A-6, Rg III, projeté), et de tous autres cotés, par des parties non subdivisées du lot 1-A, rang LU, canton de Gore ; Mesurant cinquante pieds (50') de largeur, dans ses lignes nord-est et sud-ouest, sur une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes nord-ouest et sud-est, contenant une superficie de cinq mille pieds carrés (5,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; La ligne sud-est dudit emplacement est parallèle à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang ILL, dudit canton, et est située à une distance de deux cent soixante-sept pieds (267') au nord-ouest de celle-ci; La ligne sud-ouest dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang ILL, dudit canton, et est située à une distance de deux mille cent soixante et onze pieds (2,171') de la ligne de division des rangs II et III dudit canton, Cette distance étant mesurée le long de la ligne de division des lots 1-A et 1-B, dudit canton, en allant vers le sud-ouest; Cet emplacement porte le numéro cent quatre-vingt-seize (No-196) sur un plan de subdivision projetée, préparé par Leopold Moretti, a.g.en date du quatre août, mil neuf cent soixante-six, portant le numéro C-6478; Tel que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, y attachées.Le tout sans bâtisse.Taxes municipales: $19.33.Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number seventy-eight, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Municipality of the Township of Gore Hogan Bousquet, 11163 Pie IX, Montreal, P.Q \u2014 A vacant lot located in the County of Argenteuil, known and described as consisting of lots numbers one hundred twenty-six and one hundred twenty-seven of the official subdivision of original lot number one, letter \"A\" in the Second Range (l-A-126 and 127, R.H) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Registration Division of Argenteuil; Said emplacement measuring one hundred feet (100') in width on its northwest and southeast lines by one hundred feet (100') in depth on its southwest and northeast lines and covering and area of ten thousand square feet (10,000 sq.ft.).Municipal taxes: $26.20.Yvon Boudreau, 6976 Querbes, Montreal, P.Q.\u2014 A vacant lot located in the County of Argenteuil, known and described as being part of original lot number one, letter \"A\" In the Third Range (Pt 1-A, Rge III), on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Registration Division of Argenteuil; Bounded as follows: on the southwest by a proposed street forty feet (40') in width, being part of said lot 1-A 'Range LU (l-A-6, R.IH.proposed) and on all other sides by nonsubdivided parts of lot 1-A, Range ID, Township of Gore; Measuring fifty feet (50') in width on its northeast and southwest lines, by one hundred feet (100') in depth on its northwest and southeast lines, covering an area of five thousand square feet (5,000 sq.ft.), English measure, more or less; The southeast line of said emplacement is parallel to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range III, said Township, and is located at a distance of two hundred sixty-seven feet (267') to the northwest of said line; The southwest line of said emplacement is perpendicular to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range HI, said Township, and located at a distance of two thousand one hundred seventy-one feet (2,171') from the dividing line between Ranges II and IH of said Township, this distance being measured along the dividing line between lots 1-A and 1-B of said Township in a southwesterly direction; This emplacement bears number one hundred ninety-six (No'/196) on the proposed subdivisions plan prepared by Leopold Moretti, q.l.s., on August fourth, one thousand nine hundred sixty-six, bearing number C-6478; As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching thereto.The whole without buildings.Municipal taxes: $19.33. 2030 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 Armand Papineau, 422 Grande Côte, St.Eustache, Que \u2014 La moitié indivise (de communauté) dans un emplacement d'été situé à Dunany, connu et désigné sous le lot numéro un et deux, de la subdivision officielle du lot originaire numéro un A, aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, dans le deuxième rang (1A-1 et 2, R.2) mesurant chacun desdits lots, cinquante pieds (50') de largeur par cent pieds (100') dc profondeur, mesure anglaise et plus ou moins.Avec une maison d'été dessus construite et avec les servitudes y constituées.Registration Nos: 137277 et 137278.Taxes municipales: $129.59.Jean Beaulieu, 3931, St-André, Montréal, Que \u2014 Un emplacement faisant partie du lot originaire numéro un, lettre « A», dans le Troisième Rang (Ptie 1-A, R.Ill), aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil; Borné au nord-est, par une rue projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant partie dudit lot 1-A, rang III (l-A-7, R.III, projeté), et de tous autres côtés, par des parties non subdivisées dudit lot 1-A, rang III, canton de Gore; Mesurant cinquante pieds (50') de largeur, dans ses lignes nord-est et sud-ouest, sur une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes nord-ouest et sud-est, contenant une superficie de cinq mille pieds carrés (5,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; La ligne sud-est dudit emplacement est parallèle à la ligne de division des lots 1-A et 1-B, rang III, canton dc Gore, et est située à une distance de sept cent soixante-sept pieds (767') au nord-ouest de celle-ci; La ligne nord-est dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division entre les hits 1-A et 1-1!, rang ITI, dudit canton, et est située à une distance de deux mille trois cent soixante et onze pieds (2,371') de la ligne de division des rangs II et ITI dudit canton, cette distance étant mesurée le long de la ligne de division des lots 1-A et 1-B, dudit canton, en allant vers le sud-ouest; Cet emplacement porte le numéro deux cent onze (No 211), sur un plan de subdivision projetée, préparé par Leopold Moretti, a.o.Tel que le tout se trouve présentement, avec tovites les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit emplacement; Le tout sans bâtisse; Avec droit de passage avec tous autres y ayant droit, dans les rues projetées communiquant audit emplacement, aux lacs, à la piscine et aux plages, mais la vende-resse ne sera pas tenue responsable d'aucun dommage pouvant découler à la suite d'accident survenu sur ces-dits terrains.Taxes municipales: $19.33.Paul Chouinard, 8019, St-Denis, Montréal.\u2014 Un emplacement connu et désigné sous le lot numéro deux cent quarante-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un, lettre « A », rang II, (l-A-247, Armand Papineau, 422 Grande Côte, St.Eustache, P.Q.- The undivided half (community) of a summer emplacement located in Dunany, known and described as lot number one and two of the official subdivision of original lot number one A on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, in the Second Range (1 A-1 and 2, R.2), each lot measuring fifty feet (50') in width by one hundred feet (100') in depth, English measure and more or less.With a summer house erected thereon and all servitudes established thereon.Registration Nos.137277 and 137278.Municipal taxes: $129.59.Jean Beaulieu, 3931 St.André, Montreal.P.Q.\u2014 An emplacement being part of original lot number one, letter \"A\", in the Third Range (Pt.1-A, R.Ill) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Registration Division of Argenteuil; Bounded on the northeast by a proposed street that is to measure forty feet (40') in width, being part of said lot 1-A, Range III.and on all other sides by non-subdivided parts of said lot 1-A, Range III, Township of Gore; Measuring fifty feet (50') in width on its northeast and southwest lines by one hundred feet (100') in depth on its northwest and southeast lines, covering an area of five thousand square feet (5,000 sq.ft.), English measure, more or less; The southeast line of said emplacement is parallel to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range HI, Township of Gore and is located at a distance of seven hundred sixty-seven feet (767') to the northwest of said line; The northeastern line of said emplacement being perpendicular to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range III.Township of Gore, and being located at a distance of two thousand three hundred seventy-one feet (2,371') from the dividing line between Ranges II and III of said Township, this distance being measured along the dividing line between lots 1-A and 1-B.in said Township, in a southwesterly direction; This emplacement bears number two hundred eleven (No.211) on the proposed subdivision plan prepared by Leopold Moretti, q.l.s.As the whole now subsists with all active and passive, apparent or nonapparent servitudes attaching to said emplacement; The whole without buildings; With a right-of-way, with all others having a right thereto, in the proposed streets to communicate with said emplacement, and with the lakes, swimming pool and beaches; the vendor may nevertheless not be held responsible for any damage resulting from any accident which may occur on said land.Municipal taxes: $19.33.Paul Chouinard, 8019 St.Denis, Montreal.An emplacement known and described as lot number two hundred forty-seven of the official subdivision of original lot number one, letter \"A\", Range II, (l-A-247, GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 19% 106' année, n° 10 2031 R.II) des plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement du comté d'Argenteuil.Taxes municipales: $19.33.Bernard Courchesne, 4171 - 42e Avenue, Montréal.Un emplacement dans le canton de Gore, dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné sous partie du lot numéro soixante-dix de la subdivision officielle du lot originaire numéro dix-sept B (No 17B Ptie 70) sur le plan et au livre de renvoi officiels du canton de Gore, rang II, mesurant quatre-vingt-cinq pieds de largeur sur quatre-vingt-quatre pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, borné en front, par une rue, en profondeur par le résidu dudit lot No.17B-70, d'un côté, par une autre rue et de l'autre côté, par une partie du lot numéro 17B-69 du même cadastre.Avec un chalet dessus construit.Taxes municipales: $78.56.Jacques Cormier, 11517, Olier, Montréal.\u2014 Un emplacement situé à Lakefield dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant le lot numéro dix-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro dix-huit dans le rang deux (18-18 R.II) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil.Taxes municipales: $19.33.Paul E.Côté, 1576, rue Logan, Montréal, Que.\u2014 Un emplacement situé à Lakefield dans ie comté d'Argenteuil connu et désigné comme étant une partie du lot originaire numéro dix-huit dans le rang deux (ptie 18, rg II) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil.Cet emplacement est situé dans l'angle sud-est formé par les rues 18-65 et 18-67 et mesure cent vingt pieds (120') en front sur ladite rue 18-67, la ligne sud-ouest étant parallèle à la ligne nord-est.Borné aux nord-est par ladite rue 18-65, au nord-ouest par la rue 18-67, au sud-est par la ligne separative entre le lot 18 et le comté des Deux-Montagnes et au sud-ouest par une autre partie dudit lot 18.Avec un chalet dessus construit.Tel que le tout se trouve présentement sans exception ni réserve.Taxes municipales: $60.19.Aimé Duchesne, 1423 Bourbonnière, Montréal, Que.Un_ emplacement situé en la municipalité de Dunany, comté d'Argenteuil, faisant partie du lot originaire numéro un, lettre « B », dans le deuxième rang, canton de Gore,_ (ptie-l-B, rg II), division d'enregistrement du comté d'Argenteuil; Borné en front, vers le nord-ouest, par une rue projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant partie dudit lot No 1-B, rang II (l-B-207, rg II projeté), et de tous autres côtés, par des parties non subdivisées dudit lot; Mesurant cent pieds (100') de largeur, dans ses lignes nord-ouest et sud-est, par une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes sud-ouest et nord-est, contenant une superficie de dix mille pieds carrés (10,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; R.II) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, County of Argenteuil Registration Division.Municipal taxes: $19.33.Bernard Courchesne, 4171-42nd Avenue, Montreal.An emplacement in the Township of Gore, County of Argenteuil, known and described as being part of lot number seventy of the official subdivision of original lot number seventeen B (No.17B Pt.70) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Range II, measuring eighty-five feet in width by eighty-four feet in depth, English measure and more or less, bounded in front by a street, in the rear by the remainder of said lot No.17B-70, on one side by another street and on the other side by a part of lot number 17B-69 on said cadastre.With a cottage erected thereon.Municipal taxes: $78.56.Jacques Cormier, 11,517 Olier, Montreal.\u2014 An emplacement located in Lakefield in the County of Argenteuil, known and described as being lot number eighteeu of the official subdivision of original lot number eighteen in Range Two (18-18, Rge II) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Registration Division of Argenteuil.Municipal taxes: $19.33.Paul E.Côté, 1576 Logan Street, Montreal, P.Q \u2014 An emplacement located in Lakefield in the County of Argenteuil known and described as being a part of original lot number eighteen in Range Two (Pt.18, Rge II) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Registration Division of Argenteuil.This emplacement is located at the southeast angle formed by streets 18-65 and 18-67 and measures one hundred twenty feet (120') in front on said street 18-67, the southwest line being parallel to the northeast line.Bounded on the northeast by said street 18-65, on the northwest by street 18-67, on the southeast by the dividing line between lot 18 and the County of Two Mountains and on the southwest by another part of said lot 18.With a cottage erected thereon.As the whole now subsists, without exception or reservation.Municipal taxes: $60.19.Aimé Duchesne, 1423 Bourbonnière, Montreal, P.Q.- An emplacement located in the Municipality of Dunany, County of Argenteuil, being part of original lot number one, letter \"B\", in the Second Range, Township of Gore, (Pt.1-B, Rge II), Registration Division for the County of Argenteuil; Bounded in front, towards the northwest, by a proposed street to measure forty feet (40') in width, being part of said lot No.1-B, Range II (l-B-207, Rge II, proposed) and on all the other sides by un-subdivided parts of said lot; Measuring one hundred feet (110') in width on its northwest and soushteast lines, by one hundred feet (100') in depth on its southwest and northeast lines, covering an area of ten thousand square feet (10,000 sq.ft.), English measure, more or less; 2032 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 La ligne nord-ouest dudit emplacement est parallèle à la ligne de division entre les lots-numéros 1-A et 1-B, rang II, dudit canton, et est située à une distance de huit cent cinquante-sept pieds (857') au sud-est de celle-ci ; La ligne nord-est dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division entre les lots numéros 1-A et 1-B, rang II, et est située à une distance d'environ quatre cent trente-deux pieds et soixante-huit centièmes de pied (432.68') au sud-ouest de la ligne de division entre les rangs II et III dudit canton; cette distance étant mesurée le long de la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang II, dudit canton, en allant vers le nord-est; Cet emplacement porte les numéros deux cent trente-cinq et deux cent trente-six (Nos 235 et 236) sur un plan de subdivision projetée, préparé par Leopold Moretti, a.G.en date du cinq décembre, rail neuf cent soixante-trois; Tel que ledit emplacement se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, y attachées; Avec un camp d'été dessus à être construit par la venderesse, et avec droit de passage avec tous autres y ayant droit, dans les rues communiquant audit emplacement, au lac et à la plage, mais la venderesse ne sera pas tenue responsable d'aucun dommage pouvant découler à la suite d'accident survenu sur cesdits terrains.Taxes municipales: $131.90.Lucien Dupéré, 4680, Brébeuf, Montréal, (Que.) \u2014 Un emplacement situé dans le canton de Gore, dans le comté d'Argenteuil, composé du lot numéro quinze subdivision officielle du lot originaire numéro seize B (No 16-B-15) et du lot numéro trente-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro seize B (No 16-B-39) sur le plan et au livre de renvoi officiels du canton de Gore, rang II.Avec un chalet dessus construit.Taxes municipales: $63.14.André Debbas, 1225, St-Marc, app.208, Montréal, (Que.) - ' Un emplacement situé à Lakefield dans le comté d'Argenteuil connu et désigné comme étant le lot numéro trente-quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro dix-sept « B » dans le rang deux (17B-34, rg H) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil.Taxes municipales: $19.33.Léo Drolet, 5115, Terrace Labrouse, St-Hubcrt, (Que.) - Un emplacement situé en la municipalité de Dunany, comté d'Argenteuil, faisant partie du lot originaire numéro un, lettre « B », dans le troisième rang, canton de Gore (Ptie 1-B, rg III), division d'enregistrement du comté d'Argenteuil; Borné au sud-ouest, par une rue projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant partie dudit lot 1-B, rang III (l-B-286, rg III, projeté), et de tout autres côtés, par des parties non subdivisées dudit lot 1-B, rang III, canton de Gore; The northwest line of said emplacement is parallel to the dividing line between lots numbers 1-A and 1-B, Range II, of said Township, and is located at a distance of eight hundred fifty-seven feet (857') to the southeast of the latter; The northeast line of said emplacement is perpendicular to the dividing line between lots numbers 1-A and 1-B, Range II, and is located at a distance of about four hundred thirty-two and sixty-eight hundredths feet (432.68') to the southwest of the dividing line between Ranges II and III of said Township; Said distance is measured along the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range II, said Township, in a northeasterly direction.This emplacement bears numbers two hundred thirty-five and two hundred thirty-six (Nos.235 and 236) on the proposed subdivision plan prepared by Leopold Moretti, q.l.s., on December fifth, one thou-sans nine hundred sixty-three; As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching thereto; With a summer cottage to be erected thereon by the vendor, with a right-of-way, with all others having a right thereto, in the streets to communicate with said emplacement and with the lake and beach; however the vendor may not be held responsible for any damage resulting from any accident which may occur on said land.Municipal taxes: $131.90.Lucien Dupéré, 4680 Brébeuf, Montreal, P.Q \u2014 An emplacement located in the Township of Gore, County of Argenteuil, consisting of lot number fifteen of the official subdivision of original lot number sixteen B (No.16-B-15) and lot number thirty-nine of the official subdivision of original lot number sixteen B (No.16-B-39) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Range II.With a cottage erected thereon.Municipal taxes: $63.14.André Debbas, 1225 St.Marc, Apt.208, Montreal, P.Q.- An emplacement located in Lakefield in the County of Argenteuil, known and described as being lot number thirty-four of the official subdivision of original lot number seventeen \"B\" in Range Two (17B-34, Rge II) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Registration Division of Argenteuil.Municipal taxes: $19.33.Léo Drolet, 5115 Terrace Labrouse, St.Hubert, P.Q.An emplacement located in the Municipality of Dunany, County of Argenteuil, being part of original lot number one, letter \"B\", in the Third Range, Township of Gore, County of Argenteuil Registration Division; Bounded on the southwest by a proposed street forty feet (40') in width, being part of said lot 1-B Range III (l-B-286, Rge III, proposed), and on all other sides by nonsubdivided parts of said lot 1-B Range in, Township of Gore; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106- année, n° 10 2033 Mesurant cent pieds (100') de largeur, dans ses lignes nord-est et sud-ouest, par une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes nord-ouest et sud-est, contenant une superficie de dix mille pieds carrés (10,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; La ligne nord-ouest dudit emplacement est parallèle à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang III, canton de Gore, et est située à une distance de quatre cent cinquante-sept pieds (457') au sud-est de celle-ci; La ligne sud-ouest dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang III, dudit canton de Gore, et est située à une distance de mille quatre cent cinquante et un pieds (1451') de la ligne de division des rangs II et III, dudit canton, cette distance étant mesurée le long de la ligne de division des lots 1-A et 1-B dudit canton, en allant vers le sud-ouest; Cet emplacement porte les numéros deux cent soixan-te-rjiiinze et deux cent soixante-seize (Nos 275 et 276) sur un plan de subdivision projetée.Taxes municipales: $119.97.Nirmal Gidda, 6442, rue Sherbrooke, Montréal, (Que.) - Ce certain terrain sis et situé dans la municipalité de Gore, lakefield, dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant une partie du lot originaire numéro douze B, dans le premier rang (ptie 12B, premier rang) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore; ledit terrain étant de forme irrégulière et borné comme suit: en front, au nord-ouest, d'un côté au sud-ouest et de l'autre côté au nord-est par d'autres parties dudit lot originaire No 12B et à l'arrière au sud-est par une partie du lot originaire No 13 dudit premier rang; ledit terrain mesurant deux cent cinquante pieds en largeur dans ses lignes nord-ouest et sud-est sur une profondeur de deux cent quatre-vingt-neuf pieds dans ses lignes sud-ouest et nord-est, et contenant une superficie totale de soixante-douze mille deux cent cinquante pieds carrés (72,250 p.c), l'angle sud-ouest de ladite partie étant située à une distance de mille quatre-vingt-dix pieds du chemin public (Chemin Gore) et l'angle sud-est de ladite partie étant située à une distance de mille cent trente-trois pieds du chemin public (Chemin Gore) ; la ligne nord-ouest est parallèle à la ligne dc division entre les lots originaires 12B et 12A, premier rang, canton de Gore, et est située à une distance de six cent soixante-huit pieds (668') de celle-ci; la ligne sud-est de ladite partie étant elle-même la ligne de division entre les lots originaires Nos 12B et 13, premier rang, canton de Gore, le tout en mesures anglaises et plus ou moins.Sans bâtisse y érigée.Tel que le tout se trouve actuellement avec tous les droits membres et circonstances y rattachés, sans réserve ni exception et avec tous les droits de passage dans les rues ou routes afin de communiquer du terrain décrit ci-dessus au chemin public.Taxes municipales: $43.03.Measuring one hundred feet (100') in width on its northeast and southwest lines by one hundred feet (100') in depth on its northwest and southeast lines, covering an area of ten thousand square feet (10,000 sq.ft.), English measure, more or less; The northwest line of said emplacement is parallel to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range III, Township of Gore, and is located at a distance of four hundred fifty-seven feet (457') to the southeast of the latter; The southwest line of said emplacement is perpendicular to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range III.said Township of Gore, and is located at a distance of one thousand four hundred fifty-one feet (1,451') from the dividing line between Ranges II and III, of said Township, this distance being measured along the dividing line between lots 1-A and 1-B of said Township, in a southwesterly direction; This emplacement bears numbers two hundred seventy-five and two hundred seventy-six (Nos.275 and 276) on the proposed subdivision plan.Municipal taxes: $119.97.Nirmal Gidda, 6442 Sherbrooke St., Montreal, P.Q.- That certain piece of land lying and situate in the Municipality of Gore, Lakefield in the County of Argenteuil, known and designated as being a part of original lot number twelve B, in the First Range (P.12B, First Range) on the official plan and book of reference of the Township of Gore, of rectangular figure, bounded as follows: in front to the northwest, on one side to the southwest and on the other side to the northeast by other parts of said original lot No.12B.and at the rear to the southeast by a part of original lot No.13 of said First Range, measuring said part two hundred and fifty feet in width in its northwest and southeast lines by a depth of two hundred and eighty-nine feet in its southwest and northeast side lines, and having a total superficial area of seventy-two thousand two hundred and fifty square feet (72,250 sq.ft.), the southwest angle of said part being located at a distance of one thousand ninety feet of the public road (Gore Road), and the southeast angle of said part being located at a distance of one thousand one hundred and thirty-three feet of the public road (Gore Road) and the northwest line being parallel to and located at a distance of six hundred and sixty-eight feet (668) from the division line between original lots 12B and 12A, First Range, Township of Gore, and the southeast line of said part being itself the division line between original lots Nos.12B and 13, First Range, Township of Gore, the whole English measure and more or less.Without any building thereon erected.As the whole now subsists with all its right members and appurtenances, thereto attached without any exceptions nor reserve and moreover with all rights of way in the streets or roads to communicate from the emplacement hereinabove described to the public road.Municipal taxes: $43.03. 2034 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 Marcel Girard, 2305 boul.Lévesque, Laval.\u2014 Un emplacement situé à Lakefield, dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant la partie nord du lot numéro sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro seize « A » dans le rang deux (16A partie 7, rang II) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil.Cet emplacement mesure soixante-quinze pieds en front (75') dans sa ligne ouest, sur cent quarante-deux pieds (142') dans sa ligne nord.Borné au nord par le lot 16A-6, à l'ouest par le lot 16A-4, étant une rue, à l'est par la rive du Lac Clovis et au sud par le résidu de lot 16A-7.La ligne sud étant parallèle à la ligne nord.Avec un chalet dessus construit.Taxes municipales: $24.61.Sidney Greenberg, 4800, 12e Avenue, Laval, (Que.).Un terrain situé à Lakefield dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant le lot numéro soixante-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro dix-sept « A » dans le deuxième rang (17A-69, rg II) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore.Contenant une superficie de 18,480 pieds carrés, plus ou moins.Taxes municipales: $19.33.Bertrand Gagné, 5555, rue Gérard, St-Hubert.\u2014 Un emplacement vacant situé dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant composé d'une partie du lot originaire numéro un, lettre « B », dans le troisième rang (ptie 1-B, rg III), aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil; Borné comme suit: en front, du côté sud-est, par une rue projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant partie du lot 1-B, rang III (l-B-4, rg III, projeté), et de tous autres côtés, par d'autres parties non subdivisées dudit lot 1-B, rang 111, canton de Gore; Mesurant cent pieds (100') de largeur, dans ses lignes sud-est et nord-ouest, sur une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes nord-est et sud-ouest, contenant une superficie de dix mille pieds carrés (10,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; La ligne nord-ouest dudit emplacement est parallèle à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang 111, canton de Gore, et est située à une distance dc deux cent quarante pieds (240') au sud-est de celle-ci; La ligne sud-ouest dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang III, canton de Gore, et est située à une distance de deux mille deux cent quarante et un pieds (2,241') de la ligne de division des rangs II et III, dudit canton cette distance étant mesurée le long de la ligne de division des lots 1-A et 1-B, dudit canton, en allant vers le sud-ouest; Cet emplacement porte les numéros cent soixante-quinze et cent soixante-seize (Nos 175 et 176) sur un plan de subdivision projetée.Taxes municipales: $19.33.Marcel Girard, 2305 Lévesque Blvd., Laval.\u2014 An emplacement located in Lakefield, County of Argenteuil, known and described as being the north part of lot number seven of the official subdivision of original lot number sixteen \"A\" in Range Two, (16A Pt.7, Rge II) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Registration Division of Argenteuil.This emplacement measures seventy-five feet (75') in front on its west line by one hundred forty-two feet (142') on its north line.Bounded on the north by lot 16A-6, on the west by lot 16A-4, which is a street, on the east by the shore of Lake Clovis and on the south by the remainder of lot 16A-7.The south line is parallel to the north line.With a cottage erected thereon.Municipal taxes: $24.61.Sidney Greenberg, 4800-12th Ave., Laval, P.Q.\u2014 An emplacement located at Lakefield in the County of Argenteuil, known and designated as being lot number sixty-nine of the official subdivision of the original lot number seventeen \"A\" in the second range (17A-69, Rg.II) upon the official plan and book of reference of the Township of Gore.Containing a superficial area of 18,480 square feet more or less.Municipal taxes: $19.33.Bertrand Gagné, 5555 Gérard Street, St.Hubert.\u2014 A vacant emplacement located in the County of Argenteuil, known and described as consisting of a part of original lot number one.letter \"B\", in the Third Range (Pt.1-B, Rge III) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Registration Division of Argenteuil; Bounded as follows: in front, on the southeast side, by a proposed street forty feet (40') in width, being part of lot 1-B, Range HI (l-B-4, Rge III, proposed), and on all other sides by other nonsubdivided parts of said lot 1-B, Range in, Township of Gore; Measuring one hundred feet (100') in width on its southeast and northwest lines by one hundred feet (100') in depth on its northeast and southwest lines, covering an area of ten thousand square feet (10,000 sq.ft.), English measure, more or less; The northwest line of said emplacement is parallel to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range III, Township of Gore, and is located at a distance of two hundred forty feet (240') to the southeast of the latter; The southwest line of said emplacement is perpendicular to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range III, Towhsnip of Gore, and is located at a distance of two thousand two hundred forty-one feet (2,241') from the dividing line between Ranges n and III, of said Township, the latter distance being measured along the dividing line between lots 1-A and 1-B, of said Township, in a southwesterly direction; Said emplacement is known as numbers one hundred seventy-five and one hundred seventy-six (Nos.175 and 176) on a proposed subdivision plan.Municipal taxes: $19.33. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 2035 Gaston Gendron, 2095, 1ère Ave., Québec.\u2014 Un emplacement situé à Lakefield, dans le comté d Argenteuil, connu et désigné comme étant le lot numéro quarante-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatorze A, dans le rang trois (14A-48 rg LU), aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil.Taxes municipales: 819.33.Denis Gyoffy, 8663, Anthony, app.1, Pierrefonds.\u2014 Un emplacement vacant, connu et désigné comme étant une partie du lot originaire onze lettre « A » dans le rang quatre (ptie 11A, rg IV) aux plan et livre de renvoi officiels du canton Gore.De forme irrégulière, mesurant cinquante-cinq pieds \" (55') en front dans sa ligne est, quarante-cinq pieds (45') en arrière dans sa ligne ouest, cent quarante-cinq pieds (145') d'un côté dans sa ligne nord et cent cinquante pieds (150') de l'autre côté, dans sa ligne sud et contenant en superficie sept mille trois cents pieds carrés (7,300 p.c.) le tout mesure anglaise et plus on moins.Borné à l'est par la rue 11A-62, dit rang, dit cadastre, à l'ouest par le Lac Solar, au nord par le passage 11A-68, dit rang, dit cadastre, et au sud par une autre partie dudit lot 11A; Ce dit emplacement apparaît de plus comme le lot 16, Block 32, sur un projet de subdivision connu des parties.Taxes municipales: 819.33.Mme R.Hurtubise, 937, rue Laçasse, Montréal, (O**-)-\u2014 .Un emplacement situé en la municipalité de Dunany, comté d'Argenteuil, faisant partie du lot originaire numéro un, lettre « B », dans le deuxième rang, du canton de Gore, (ptie 1-B, rg II) division d'enregistrement du comté d'Argenteuil; Borné en front, vers le nord-ouest, par une rue projetée de quarante (40') pieds de largeur, étant partie dudit lot numéro 1-B, rang II, (l-B-30, rg II projeté), et de tous autres côtés, par des parties non subdivisées dudit lot; mesurant cinquante pieds (50') de largeur, dans ses lignes nord-ouest et sud-est, par une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes sud-ouest et nord-est, contenant une superficie de cinq mille pieds carrés (5,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; La ligne nord-ouest de cet emplacement est parallèle à la ligne de division entre les lots numéros 1- et 1-B, et est située à une distance de cent trente-sept pieds (137') au sud-est de celle-ci; La ligne nord-est dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division entre les lots numéros 1-A et 1-B, et est située à une distance d'environ huit cent trente-deux pieds et soixante-huit centièmes de pied (832.68') au sud-ouest de la ligne de division entre les rangs II et III dudit canton, cette distance étant mesurée le long de la ligne de division entre les lots numéros 1-A et 1-B, rang II, dudit canton; Cet emplacement porte le numéro trente-neuf (No 39), sur un plan de subdivision projetée, préparé par Leopold Moretti, s.c Gaston Gendron, 2095 - 1st Avenue, Québec.\u2014 An emplacement located in Lakefield, in the County of Argenteuil, known and described as being lot number forty-eight of the official subdivision of original lot number fourteen A, in Range Three (14A-48, Rge III), on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Argenteuil Registration Division.Municipal taxes: 819.33.Denis Gyoffy, 8663 Anthony, Apt.1, Pierrefonds.\u2014 A vacant lot, known and described as being a part of original lot eleven, letter \"A\", in Range Four (Pt.11 A, Rge IV) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore.Of irregular configuration, measuring fifty-five feet (55') in front on its east line, forty-five feet (45') in rear on its west line, one hundred forty-five feet (145') on one side on its north line and one hundred fifty feet (150') on the other side on its south line, and covering an area of seven thousand three hundred square feet (7,300 sq.ft.), the whole in English measure and more or less.Bounded on the east by the street 11A-62, said Range, said cadastre, on the west by Lake Solar, on the north by a passage 11A-68 said Range, said cadastre and on the south by another part of said lot 11A; Furthermore, said emplacement is shown as lot 16, Block 32, on a proposed subdivision known to the parties.Municipal taxes: 819.33.Mrs.R.Hurtubise, 937 Laçasse St., Montreal, P.Q.\u2014 .An emplacement located in the Municipality of Dunany, County of Argenteuil, forming part of original lot number one, letter \"B\", in the Second Range of the Township of Gore, (Pt.1-B, Rge II) County of Argenteuil Registration Division; Bounded in front, towards the northwest, by a proposed street forty feet (40') in width, being a part of said lot number 1-B, Range II (l-B-30, Rge II, proposed), and on all other sides by unsubdivided parts of said lot; measuring fifty feet (50') in width, on its northwest and southeast lines, by one hundred feet (100') in depth on its southwest and northeast lines, covering an area of five thousand square feet (5,000 sq.ft.), English measure, more or less; The northwest line of said emplacement is parallel to the dividing line between lots numbers 1-A and 1-B, and is located at a disrance of one hundred thirty-seven feet (137') to the southeast of the latter; The northeast line of said emplacement is perpendicular to the dividing line between lots numbers 1-A and 1-B, and is located at a distance of approximately eight hundred thirty-two and sixty-eight hundredths feet (832.68') to the southwest of the dividing line between Ranges II and III of said Township, the latter distance being measured along the dividing line between lots numbers 1-A and 1-B, Range n, of said Township; Said emplacement bears number thirty-nine (No.39), on a proposed subdivision plan, prepared by Leopold Moretti, q.l.s.; 2036 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 Tel que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit emplacement; Le tout sans bâtisse, et avec droit de passage avec tous autres y ayant droit, dans les rues communiquant audit emplacement, au lac et à la plage.Taxes municipales: $19.33.Joseph Horvath, 7448, de l'Épée, Montréal.\u2014 Un emplacement situé à Lakefield, comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant une partie du lot onze, lettre « B », dans le quatrième rang (ptie 11B, rg IV) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore.De forme irrégulière, ayant front sur le chemin public, mesurant quarante pieds (40') de front dans sa ligne nord-ouest, environ soixante-dix pieds (70') à l'arrière dans sa ligne sud-est le long du lac Evans, environ cent pieds (100') d'un côté dans sa ligne sud-ouest, et environ cent soixante pieds (160') dans sa ligne nord-est et contenant une superficie de 6,500 pieds carrés, le tout en mesures anglaises, et plus ou moins; Borné en front au nord-ouest par le chemin public, à l'arrière au sud-est par le lac Evans, d'un côté, au nord-est, par une autre partie dudit lot 11B appartenant à Cunningham, et de l'autre côté, au sud-ouest, par une autre partie dudit lot 11B, propriété de Albert Leroux.Ledit emplacement est connu comme étant le lot 4A, bloc 8, sur un plan de subdivision projetée connu des parties.Y compris un chalet dessus érigé.Taxes municipales: $89.07.Mme Elizabeth Hanka, 4938, Belleville, Pierrefonds, (Que.).\u2014 Un terrain vague situé à Lakefield, dans la municipalité de Gore, comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant une partie du lot originaire douze, lettre « A », dans le quatrième rang (ptie 12A, rg IV), aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, comté d'Argenteuil, de forme irrégulière, mesurant cent pieds (100') dans sa ligne ouest, cent cinquante pieds (150') dans sa ligne sud, soixante-quinze pieds (75') dans sa ligne est, vingt pieds (20') sur une partie de sa ligne nord (ladite partie de ligne est perpendiculaire à la ligne ouest dudit emplacement d'où elle part) et cent trente-deux pieds et trente-huit centièmes de pied (132.38') dans une autre ligne nord commençant sur la ligne est et remontant à l'autre ligne nord de vingt pieds (20') ci-dessus mentionnée, et contenant une superficie de 13,375 pieds carrés, mesures anglaises et plus ou moins.Les lignes est et ouest sont parallèles et perpendiculaires à la ligne sud dudit emplacement; Ladite partie est bornée au sud par le lot 12-A-44 dudit cadastre et par la moitié est du lot 12A-45 dudit cadastre, à l'est par une partie du lot originaire 12B dudit cadastre, à l'ouest par une autre partie dudit lot 12A, et au nord par d'autres parties dudit lot 12A.Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes y rattachées.Taxes municipales: $19.33.As the whole now subsists, with all active and passive, apparent or nonapparent servitudes attaching to said emplacement; The whole without buildings, and subject to a right-of-way with others entitled thereto, in the streets leading to said emplacement, to the lake and to the beach.Municipal taxes: $19.33.Joseph Horvath, 7448 de l'Épée, Montreal.\u2014 An emplacement at Lakefield, County Argenteuil, known and designated as being a Part of lot eleven, letter \"B\" in the Fourth Range (Pt.11B, Rge IV) on the official plan and book of reference of the Township of Gore.Of irregular form, fronting on the Public road, measuring forty feet (40') in front in its northwest line, about seventy feet (70') in rear in its southeast line along Lake Evans, about one hundred feet (100') on one side in its southwest line, and about one hundred and sixty feet (160') in its northeast line and having a surface area of 6500 square feet, the whole English measure and more or less; Bounded in front to the northwest by the public road, in rear to the southeast by Lake Evans, on one side to the northeast by another part of said lot 11B belonging to Cunningham, and on the other side to the southwest by another part of said lot 11B belonging to Albert Leroux.Said emplacement known as lot 4A, Block 8 on a proposed subdivision plan known to the parties.With a cottage thereon erected.Municipal taxes: $89.07.Mrs.Elizabeth Hanka, 4938 Belleville, Pierrefonds, P.Q.- A vacant emplacement situated at Lakefield to the Municipality of Gore, County of Argenteuil, known and designated as being a part of the original lot twelve letter \"A\", in the Fourth Range (Pt.12A Rge IV) on the official plan and book of reference of the Township of Gore, County of Argenteuil, of irregular figure, measuring one hundred feet (100') in its west line, one hundred and fifty feet (150') in its south line, seventy five feet (75') in its east line, twenty feet (20') in a portion of its north line (this said portion starts perpendicularly from the west line of the said emplacement) and one hundred and thirty-two feet and thirty-eight hundredths of a foot (132.38') in another north line commencing at the east line and going up to the other north line of twenty feet (20') mentioned before, and having a superficial area of 13,375 square feet, English measure and more or less.The east and west lines are parallel, and perpendicular to the south line of the said emplacement; Bounded the said part: to the south by lot 12-A-44, said cadastre and by the east half of lot 12A-45, said cadastre, to the east by Part of the original lot 12B, said cadastre, to the west by another Part of said lot 12A, and to the north by other Parts of said lot 12A.As the whole now subsists with all the servitudes attached thereto.Municipal taxes: $19.33. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 2037 Napoléon Lelièvre, 12132, rue Pigeon, Montréal Nord.\u2014 Un emplacement situé à Lakefield, dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant le lot numéro vingt-neuf de la subdivision du lot originaire numéro seize « B » dans le rang deux (16B-29, rg II) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil.Taxes municipales: $71.54.André Leblanc, 610 rue DeLinelle, Montréal, (Que.).Un emplacement situé dans le comté d'Argenteuil connu et désigné comme étant composé d'une partie du lot originaire numéro un, lettre « A », dans le troisième rang (ptie 1-A, rg III) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil; Borné comme suit: au nord-est, par une rue projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant partie du lot 1-A, rang III (l-A-2 projeté), et de tous autres côtés, par des parties non subdivisées dudit lot 1-A, rang 111, canton de Gore; Mesurant cent pieds (100') de largeur, dans ses lignes nord-est et sud-ouest, sur une profondeur de cent pieds (100'), dans ses lignes nord-ouest et sud-est, contenant une superficie de dix mille pieds carrés (10,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; La ligne sud-est dudit emplacement est parallèle à la ligne de division des lots 1-A et 1-B, rang III, canton de Gore, et est située à une distance de sept cent quarante pieds (740') au nord-ouest de celle-ci ; La ligne sud-ouest dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang HI, dudit canton, et est située à une distance de mille soixante-onze pieds (1,071') de la ligne de division des rangs II et III, dudit canton, cette distance étant mesurée le long de la ligne de division des lots 1-A et 1-B, dudit canton en allant vers le sud-ouest; Cet emplacement porte les numéros trente et un et trente-deux (Nos 31 et 32), sur un plan de subdivision projetée, préparé par Leopold Moretti, a.g.en date du quatre août, mil neuf cent soixante-six, portant le No C-6478.Taxes municipales: $19.33.Real Lanctot, 130 rue Principale, St-Basile LeGrand.Un emplacement vacant situé dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant une partie du lot originaire numéro un, lettre « B », dans le troisième rang, (ptie 1-B, rg III), aux plan et livre de renvoi officiels du canton Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil; Borné au sud-est, par une rue projetée de quarante pieds (400 de largeur, étant partie du lot 1-B, rang III (l-B-3, rg LU, projeté), du côté nord-ouest par partie du lot 1-A, rang III, canton de Gore, et de tous autres côtés, par des parties non subdivisées dudit lot 1-B, rang III, canton de Gore; Napoléon Lelièvre, 12132 Pigeon Street, Montreal-North.\u2014 An emplacement located in Lakefield, in the County of Argenteuil, known and described as being lot number twenty-nine of the subdivision of original lot number sixteen \"B\" in Range Two (16B-29, Rge II) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Argenteuil Registration Division.Municipal taxes: $71.54.André Leblanc, 610 DeLinelle St., Montreal, Que.\u2014 An emplacement located in the County of Argenteuil, known and described as forming part of original lot number one, letter \"A\", in Range Three (Pt.1-A, R.Ill) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Argenteuil Registration Division; Bounded as follows: on the northeast, by a proposed street measuring forty feet (40') in width, being part of lot 1-A, Range III (l-A-2 proposed), and on all other sides, by nnsnhdivided parts of said lot 1-A, Range III, Township of Gore; Measuring one hundred feet (100') in width on its northeast and southwest lines, by one hundred feet (100') in depth on its northwest and southeast lines, covering an area of ten thousand square feet (10,000 sq.ft.), English measure, more or less; The southeast line of said emplacement is parallel to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range IH, Township of Gore, and is located at a distance of seven hundred forty feet (740') to the northwest of the latter; The southwest line of said emplacement is perpendicular to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range III, in said Township, and is located_at a distance of one thousand seventy-one feet (1,071') from the dividing line between Ranges II and III.in said Township, said distance being measured along the dividing line between lots 1-A and 1-B of said Township, in a southwesterly direction; Said emplacement is shown as numbers thirty-one and thirty-two (Nos.31 and 32) on a proposed subdivision plan, prepared by Leopold Moretti, q.l.s., dated August fourth one thousand nine hundred sixty-six, and bearing number C-6478.Municipal taxes: $19.33.Real Lanctol, 130 Principale Street, St.Basile Le Grand.\u2014 A vacant emplacement located in the County of Argenteuil, known and described as being a part of original lot number one, letter \"B\", in Range Three, (Pt.1-B, Rge III), on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Argenteuil Registration Division; Bounded on the southeast by a proposed street measuring forty feet (40') in width, being a part of lot 1-B, Range III (l-B-3, Rge 111, proposed), on the northwest side by a part of lot 1-A, Range III, Township of Gore, and on all other sides, by insubdivided parts of said lot 1-B, Range HI, Township of Gore. 2038 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 Mesurant cinquante pieds (50') de largeur, dans ses lignes nord-ouest et sud-est, sur une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes nord-est et sud-ouest, contenant une superficie de cinq mille pieds carrés (5,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; La ligne nord-ouest dudit emplacement se confond avec la ligne de division des lots 1-A et 1-B, rang III, dudit canton de Gore; La ligne sud-ouest dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang III, dudit canton de Gore, et est située à une distance de deux mille neuf cent quarante et un pieds (2,941') de la ligne de division des rangs II et 111 dudit canton, cette distance étant mesurée le long de la ligne de division des lots 1-A et 1-B, rang III dudit canton, en allant vers le sud-ouest; Cet emplacement porte le numéro deux cent vingt-deux (No 222) sur un plan de subdivision projetée; Tel que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit emplacement; Le tout sans bâtisse.Taxes municipales: $19.33.Paul-Armand Lavoie, 7585, rue Lajeunesse, Montréal.\u2014 Un emplacement situé en la municipalité de Dunany, comté d'Argenteuil, faisant partie dudit lot originaire numéro un, lettre « B », rang LU, canton de Gore (ptie IB, rg in) division d'enregistrement du comté d'Argenteuil.Borné au sud-est, par une me projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant partie dudit lot 1-B, rang IU, (l-B-6, rg UI projeté), et de tous autres côtés, par des parties non subdivisées dudit lot 1-B, rang III, canton de Gore; Mesurant cent pieds (100') de largeur, dans ses lignes nord-ouest et sud-est, par une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes nord-est et sud-ouest, contenant une superficie de dix mille pieds carrés (10,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; La ligne sud-est dudit emplacement est parallèle à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang 111, canton de Gore, et est située à une distance de huit cent vingt pieds (820') au sud-est de celle-ci; La ligne sud-ouest dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang III, dudit canton de Gore, et est située à une distance de mille sept cent quatre-vingt-onze pieds (1,791') de la ligne de division des rangs II et IU, dudit canton; cette distance étant mesurée le long de la ligne de division des lots 1-A et 1-B dudit canton, en allant vers le sud-ouest; Cet emplacement porte les numéros soixante-quatre et soixante-cinq (Nos 64 et 65), sur un plan de subdivision projetée, préparé par Leopold Moretti, a.O.en date du vingt-sept février, mil neuf cent soixante-quatre.Taxes municipales: $107.70.Measuring fifty feet (50') in width on its northwest and southeast lines, by one hundred feet (100') in depth on its northeast and southwest lines, covering an area of five thousand square feet (5,000 sq.ft), English measure, more or less; The northwest line of said emplacement merges with the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range LU, in said Township of Gore; The southwest line of said emplacement is perpendicular to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range III, in said Township of Gore, and is located at a distance of two thousand nine hundred forty-one feet (2,941') from the dividing line between Ranges II and 111 of said Township, said distance being measured along the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range 1U of.said Township, in a southwesterly direction ; Said emplacement is shown as number two hundred twenty-two (No.222) on a proposed subdivision plan; As the whole now subsists, with all active and passive, apparent or unapparent servitudes, attaching to said emplacement; The whole without buildings.Municipal taxes: $19.33.Paul-Armand Lavoie, 7585 Lajeunesse Street, Montreal.\u2014 An emplacement located in the Municipality of Dunany, County of Argenteuil.forming part of said original lot number one, letter \"B\", in Range IU, Townsnip of Gore (Pt.IB, R.Ill) County of Argenteuil Registration Division.Bounded on the southeast by a proposed street measuring forty feet (40') in width, being a part of said lot 1-B, Range Ul, (l-B-6, Rge IU, proposed), and on all other sides by unsubdivided parts of said lot 1-B, Range IU, Township of Gore; Measuring one hundred feet (100') in width on its northwest and southeast lines, by one hundred feet (100') in depth on its northeast and southwest lines, covering an area of ten thousand square feet (10,000 sq.ft), English measure, more or less; The southeast line of said emplacement is parallel to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range III, Township of Gore, and is located at a distance of eight hundred twenty feet (820') to the southeast of the latter; The southwest line of said emplacement is perpendicular to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range IU, in said Township of Gore, and is located at a distance of one thousand seven hundred ninety-one feet (1,791') from the divinding line between Ranges II and 111, in said Township; said distance being measured along the dividing line between lots 1-A and 1-B in said Township, in a southwesterly direct ion; Said emplacement is shown as numbers sixty-four and sixty-five (Nos.64 and 65) on a proposed subdivision plan, prepared by Leopold Moretti, q.l.s., dated February twenty-seventh, one thousand nine hundred sixty-four.Municipal taxes: $107.70. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1911,, 106' année, n° 10 2039 Lake Clearview Estate, 9878 Papineau, Montreal, (Que).- ., , Un emplacement vacant situé dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant composé d'une partie du lot originaire numéro un, lettre « A » dans le troisième rang (ptie 1-A, rg III) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil; Borné au sud-ouest, par une rue projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant partie dudit lot 1-A, rang III (l-A-6, rg III, projeté), et de tous autres côtés, par des parties non subdivisées dudit lot 1-A, rang III, canton de Gore; Mesurant cinquante pieds (50') de largeur dans ses lignes nord-est et sud-ouest, sur une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes nord-ouest et sud-est, contenant une superficie de cinq mille pieds carrés (5,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; La ligne sud-est dudit emplacement est parallèle à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang III, dudit canton, et est située à une distance de sept cent dix-sept pieds (717') au nord-ouest de celle-ci; La ligne sud-ouest dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang III, dudit canton, et est située à une distance de deux mille cent soixante et onze pieds (2,171') de la ligne de division des rangs II et III dudit canton, cette distance étant mesurée le long de la ligne de division des lots 1-A et 1-B, dudit canton en allant vers le sud-ouest; Cet emplacement porte le numéro deux cent cinq (No 205) sur un plan de subdivision projetée.Tel que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit emplacement; Le tout sans bâtisse.Taxes municipales: 819.33.Georges Morin, 991, 4e Ave., Verdun, (Que.).\u2014 Un emplacement situé en la municipalité de Dunany, comté d'Argenteuil, faisant partie du lot originaire numéro un, lettre « A », dans le troisième rang, canton de Gore (ptie 1-A, rg III) division d'enregistrement du comté d'Argenteuil; Borné au nord-est, par une rue projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant partie dudit lot 1-A, rang III (1-A-l, rg III projeté) et de tous autres côtés, par des parties non subdivisées dudit lot 1-A, rang III, canton de Gore; Mesurant cent pieds (100') de largeur dans ses lignes nord-est, et sud-ouest par une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes nord-ouest et sud-est contenant une superficie de dix mille pieds carrés (10,000 p.c.) mesure anglaise, plus ou moins.La ligne sud-est, dudit emplacement est parallèle à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang III, canton de Gore, et est située à une distance de cinq cent cinquante-sept pieds (557') au nord-ouest de celle-ci; La ligne nord-est dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, rang III, dudit canton de Gore, et est située à une dis- Lake Clearview Estate, 9878 Papineau, Montreal, Que.\u2014 A vacant emplacement located in the County of Argenteuil, known and described as consisting of a part of original lot number one, letter \"A\" in Third Range (Pt.-l-A, R.Ill) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Argenteuil Registration Division; Bounded on the southwest by a proposed street forty feet (40') in width, forming part of said lot 1-A, Range III (l-A-6, R.Ill, proposed), and on all other sides by non subdivided parts of said lot 1-A, Range III, Township of Gore; Measuring fifty feet (50') in width on its northeast and southwest lines by a depth of one hundred feet (100') on its northwest and southeast oines, covering an area of five thousand square feet (5,000 sq.ft), English measure, more or less; The southeast line of said emplacement is parallel to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range III, in said Township, and is located at a distance of seven hundred seventeen feet (717') to the northwest of the latter; The southwest line of said emplacement is perpen-cicular to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range III, of said Township, and is located at a distance of two thousand one hundred seventy-one feet (2,171') from the dividing line of Ranges II and III in said Township, said distance being measured along the dividing line between lots 1-A and 1-B, in said Township, in a southwesterly direction.This emplacement bears number two hundred and five (No.205) on a proposed subdivision plan.As the whole now subsists, with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to said emplacement; the whole without buildings.Municipal taxes: 819.33.Georges Morin, 991-4th Ave., Verdun, Que.\u2014 An emplacement located in the Municipality of Dunany, County of Argenteuil, forming part of original lot number one, letter \"A\", in the Third Range, Township of Gore (Pt.1-A, R.LTI), County of Argenteuil Registration Division; Bounded on the northeast by a proposed street forty feet (40') in width, forming part of said lot 1-A, Range III (1-A-l, R.Ill proposed) and on all other sides by non subdivided parts of said lot 1-A, Range III, Township of Gore; Measuring one hundred feet (100') in width on its northeast and southwest lines, by a depth of one hundred feet (100') on its northwest and southeast lines, covering an area of ten thousand square feet (10,000 sq.ft), English measure, more or less.The southeast line of said emplacement is parallel to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range III, Township of Gore, and is located at a distance of five hundred fifty-seven feet (557') to the northwest of the latter; The northeast line of said emplacement is perpendicular to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range III, in said Township of Gore, and is located 2040 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 tance de neuf cent trente et un pieds (931') de la ligne de division des rangs II et III, dudit canton - cette distance étant mesurée le long de la ligne de division entre les lots 1-A et 1-B, dudit canton de Gore, en allant vers le sud-ouest; Cet emplacement porte les numéros deux cent soixante-quatorze et deux cent soixante-quinze (Nos 274 et 275), sur un plan et subdivision projetée préparé par Leopold Moretti, s.c.en date du huit mai, mil neuf cent soixante-quatre.Taxes municipales: $79.83.Jean-Marie Roy, 66 rue Langevin, Hull, Que.\u2014 Un emplacement vacant situé dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant compose d'une partie du lot originaire numéro un, lettre « B », dans le deuxième rang (ptie IB; rg II), aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil; Mesurant cent pieds (100') de largeur, dans ses lignes nord-ouest et sud-est sur une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes nord-est et sud-ouest, formant une superficie de dix mille pieds carrés (10,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; Borné comme suit: en front, du nord-ouest, par une rue projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant une partie dudit lot 1-B, rang II, canton de Gore (l-B-30 projeté), canton de Gore, et de tous autres côtés, par d'autres parties non subdivisées dudit lot 1-B, rang H, canton de Gore; La ligne nord-ouest dudit emplacement est parallèle à la ligne de division des lots 1A et IB, rang II, canton de Gore, et est située à une distance de cent trente-sept pieds (137') au sud-est de celle-ci; La ligne nord-est dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division des lots 1-A et 1-B, rang n, canton de Gore et est située à une distance de mille sept cent quatre-vingt-deux pieds et soixante-huit centièmes de pied (1,782.68') de la ligne de division des rangs II et III du canton de Gore; cette distance étant mesurée le long de la ligne de division des lots 1-A et 1-B, rang n, dudit canton de Gore, en allant vers le sud-ouest; Cet emplacement porte les numéros cinquante-huit et cinquante-neuf (Nos 58 et 59), sur un plan de subdivision.Tel que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives apparentes ou occultes, y attachées.Le tout sans bâtisse.Taxes municipales: $129.95.Albini Rochon, 191 avenue Lafleur, Verdun, Que.\u2014 Un emplacement vacant situé dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant composé d'une partie du lot originaire numéro un, lettre « B », dans le troisième rang (ptie 1-B, rg III), aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil; Mesurant cinquante pieds (50') de largeur, dans ses lignes nord-ouest et sud-est, sur une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes nord-est et sud-ouest, contenant en superficie cinq mille pieds carres (5,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; at a distance of nine hundred thirty-one feet (931 ) from the dividing line between Ranges II and III in said Township \u2014 such distance being measured along the dividing line between lots 1-A and 1-B in said Township of Gore, in a southwesterly direction; This emplacement bears number two hundred and seventy-four and two hundred and seventy-five (Nos.274 and 275), on a proposed subdivision plan prepared by Leopold Moretti, q.l.s.,on May eighth, one thousand nine hundred sixty-four.Municipal taxes: $79.83.Jean-Marie Roy, 66 Langevin Street, Hull, Que.\u2014 A vacant emplacement located in the County of Argenteuil, known and described as consisting of a part of original lot number one, letter \"B\" in Second Range (Pt.IB, R.H), on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Argenteuil Registration Division; Measuring one hundred feet (100') in width on its northwest and southeast lines by a depth of one hundred feet (100') on its northeast and southwest lines, covering an area of ten thousand square feet (10,000 sq.ft.), English measure, more or less; Bounded as follows: in front, on the northwest by a proposed street forty feet (40') in width, forming part of said lot 1-B, Range II, Township of Gore (l-B-30 proposed).Township of Gore, and on all other sides by other non subdivided parts of said lot 1-B, Range H, Township of Gore; The northwest line of said emplacement is parallel to the dividing line between lots 1A and IB, Range II, Township of Gore, and is located at a distance of one hundred thirty-seven feet (137') to the southeast of the latter; The northeast line of said emplacement is perpendicular to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range II, Township of Gore, and is located at a distance of one thousand seven hundred eighty-two and sixty-eight hundredths feet (1,782.68') from the dividing line between Ranges II and III in the Township of Gore; such distance being measured along the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range H, in said Township of Gore, in a southwesterly direction.This emplacement bears numbers fifty-eight and fifty-nine (Nos.58 and 59), on a subdivision plan.As the whole now subsists, with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching thereto.The whole without buildings.Municipal taxes: $129.95.Albini Rochon, 191 Lafleur Ave., Verdun, Que.\u2014 A vacant emplacement located in the County of Argenteuil, known and described as consisting of a part of original lot number one, letter \"B\", in Third Range (Pt.1-B, Rg.Ill) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Argenteuil Registration Division; measuring fifty feet (50') in width on its northwest and southeast lines by a depth of one hundred feet (100') on its northeast and southwest lines, covering an area of five thousand square feet (5,000 sq.ft.), English measure, more or less; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 2041 Borné comme suit: au nord-ouest, par une rue projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant partie dudit lot 1-B, rang III (l-B-6, rg III, projeté), au sud-sud-est, par le lot 2-A, rang ILT, canton de Gore, et de tous autres côtés, par des parties non subdivisées dudit lot No 1-B, rang III, canton de Gore; La ligne nord-ouest dudit emplacement est parallèle à la ligne de division des lots 1A et IB, rang III, canton de Gore, et est située à une distance de huit cent soixante pieds (860') au sud-est de celle-ci; La ligne sud-ouest dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division des lots 1A et IB, rang III, canton de Gore, et est située à une distance de mille neuf cent quarante et un pieds (1,941') au sud-est de la ligne de division des rangs II et III, canton de Gore, cette distance étant mesurée le long de la ligne de division des lots 1-A et 1-B, rang LIT, canton de Gore, en allant vers le sud-ouest; Cet emplacement porte le numéro treize (No 13) sur un plan de subdivision projetée.Taxes municipales: $19.33.Me P.Fournier-Roy, 10199 Royal, Ste-Anne-de-Beaupré.\u2014 Un emplacement situé à Lakefield dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant le lot numéro six de la subdivision du lot originaire numéro quatorze « A », dans le rang III (14A-6, rg III), aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil.Taxes municipales: $19.33.Arnold Sheepwash, 149 Morin, Châteauguay, Que.\u2014 Une parcelle de terrain vague située dans la municipalité de Lakefield, comté d'Argenteuil, faisant partie du lot connu et désigné sous le numéro dix-sept « A » (ptie No 17A) du sixème rang du canton de Gore, aux plan et livre de renvoi officiels faits pour ledit canton, comté d'Argenteuil.Ledit emplacement mesurant soixante-quinze pieds (75') de largeur dans ses lignes est et ouest sur une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes latérales nord et sud, le tout en mesure anglaise et plus ou moins; Ladite parcelle de terrain ou ledit emplacement borné en front et de chaque côté par le résidu dudit lot numéro 17A, propriété du présent vendeur.La ligne ouest dudit emplacement étant parallèle à la ligne de division du lot numéro 16B, et située à une distance de cent pieds (100') de celle-ci; La ligne est dudit emplacement étant à une distance de cent pieds (100') du chemin privé d'une largeur de quarante-cinq pieds (45'), traversant ledit lot numéro 17A et parallèle à celui-ci; et la prolongation en ligne droite de la ligne latérale sud dudit emplacement jus-qu'audit chemin privé d'une largeur de quarante-cinq pieds (45') est située à une distance de deux cent quatre-vingt-sept pieds (287') du chemin public, cette mesure étant prise le long de la ligne ouest du chemin privé.Avec une maison dessus construite.Bounded as follows: on the northwest by a proposed street forty feet (40') in width, forming part of said lot 1-B, Range III (l-B-6.R.Ill, proposed), on the southeast by lot 2-A, Range III, Township of Gore, and on all other sides by non subdivided parts of said lot No.1-B, Range III, Township of Gore; The northwest line of said emplacement is parallel to the dividing line between lots 1À and IB, Range TTT, Township of Gore, and is located at a distance of eight hundred sixty feet (860') to the southeast of the latter; The southwest line of said emplacement is perpendicular to the dividing line between lots 1A and IB, Range III, Township of Gore, and is located at a distance of one thousand nine hundred and forty-one feet (1,941 ') to the southeast of the dividing line between Ranges II and III, Township of Gore, such distance being measured along the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range IIL, Township of Gore, in a southwesterly direction; This emplacement bears number thirteen (No.13) on a proposed subdivision plan.Municipal taxes: $19.33.Me.P.Fournier-Roy, 10199 Royal, Ste.Anne-de-Beaupré.\u2014 An emplacement located in Lakefield in the County of Argenteuil, known and described as being lot number six of the subdivision of original lot number fourteen \"A\", in Range LTI (14A-6, R.Ill), on the plan and in the book of reference of the official cadastre for the Township of Gore, Argenteuil Registration Division.Municipal taxes: $19.33.Arnold Sheepwash, 149 Morin, Châteauguay, Que.\u2014 A vacant piece or parcel of land situated in the municipality of Lakefield, county of Argenteuil, being part of lot known and designated under number seventeen \"A\" (Pt.No.17A) in the Sixth Range of the Township of Gore, on the ofiàcial plan and book of reference made for the said Township, county of Argenteuil.Said emplacement measuring seventy-five feet (75') in width in its east and west lines by one hundred feet (100') in depth in its north and south lateral lines, the whole english measure and more or less; Said piece or parcel of land or emplacement bounded in front and on every side by the residue of the said lot No.17A owned by the present vendor.The west line of the said emplacement being parallel and at a distance of one hundred feet (100') from the division line of lot No.16B; and The east line of the said emplacement being parallel and at a distance of one hundred feet (100') from the private road forty-five feet (45') in width crossing said lot No.17A; and the prolongation in a straight line of the south lateral line of the said emplacement up to the said private road forty-five feet (45') in width is situated at a distance of two hundred and eighty-seven (287') from the public road measured along the west line of the private road.With a house thereon erected. 2042 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 Est inclus dans la présente vente un droit de passage à perpétuité en faveur de l'acquéreur et de ses représentants dans les chemins privés traversant ledit lot numéro 17A offrant un moyen de communication en commun avec le vendeur et avec ceux qui peuvent avoir le même droit, entre le chemin public et l'emplacement vendu par les présentes.Taxes municipales: $19.33.Jean Charles Tanguay, 456 Ave des Pins, app.32, Montréal.\u2014 Un emplacement situé à St-Colomban, dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné sous les lots numéros quarante et quarante et un de la subdivision officielle du lot originaire numéro dix-sept A (Nos 17A-40 et 41) sur le plan et au livre de renvoi officiels du canton de Gore, rang II.Sans bâtisse dessus construite.Taxes municipales: $19.33.Lise Trudeau, 5065 rue Valérie, St-Léonard.\u2014 Un emplacement situé à Lakefield dans le comté d'Argenteuil, connue et désignée comme étant le lot numéro quarante-deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro dix-sept « B » dans le rang deux (17B-42, rg H) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore, division d'enregistrement d'Argenteuil.Avec un droit en commun aux lacs et aux plages du Domaine.Taxes municipales: $19.33.Ronald Tétreault, 810 Fort St-Louis, app.4, Boucherville.\u2014 Un emplacement situé à Dunany, comté d'Argenteuil faisant partie du lot originaire numéro un, lettre « B », dans le troisième rang, canton de Gore, division d'enregistrement du comté d'Argenteuil, (ptie IB, rg III) ; Borné au sud-ouest, par une rue projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant partie dudit lot 1-B, rang LU (l-B-2, rg IU, projeté) du côté sud-est, par une autre rue projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant partie dudit lot 1-B, rang III, (l-B-6, rg III, projeté), et des autres côtés, par des parties non subdivisées dudit lot 1-B, rang UI, canton de Gore; Mesurant cent pieds (100') de largeur, dans ses lignes nord-ouest, et sud-est, par une profondeur, de cent pieds (100') dans ses lignes nord-est et sud-ouest, contenant une superficie de dix mille pieds carrés (10,000 p.c.) mesure anglaise, plus ou moins; La ligne sud-est dudit emplacement est parallèle à la ligne de division des rangs 1-A et 1-B, rang ni, canton de Gore, et est située à une distance de huit cent vingt pieds (820') au sud-est de celle-ci; La ligne sud-ouest dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division entre les lots 1-A, et 1-B, rang III, dudit canton de Gore, et est située à une distance de mille six cent quatre-vingt-onze pieds (1,691') de la ligne de division des rangs U et UI dudit canton; cette distance étant mesurée le long de la ligne de division des lots 1-A et 1-B, dudit canton, en allant vers le sud-ouest; Cet emplacement porte les numéros soixante-six et soixante-sept (Nos 66 et 67) sur un plan de subdivision projetée.Taxes municipales: $54.78.Includes in the present sale a right of way for the purchaser and his representatives at perpetuity in tne private roads crossing the said lot No.17A to communicate in the common with the vendor and with those who may have the same right from the public road to the hereby sold emplacement.Municipal taxes: Jean-Charles Tanguay, 456 Des Pins Avenue, Apt.2, Montreal.\u2014 ., An emplacement located in St.Colomban, in the County of Argenteuil, known and described as lots numbers forty and forty-one of the official subdivision of original lot number seventeen A (Nos.17A-40 and 41) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore.Range II.Without any buildings erected thereon.Municipal taxes: $19.33.Lise Trudeau, 5065 Valérie Street, St.Léonard.\u2014 An emplacement located in Lakefield in the County of Argenteuil, known and described as being lot number forty-two of the official subdivision of original lot number seventeen \"B\" in Range Two (17-B-42, R.II) on the official plan and in the book of reference for the Township of Gore, Argenteuil Registration Division.With a common right to the lakes and beaches the property.Municipal taxes: $19.33.Ronald Tétreault, 810 Fort St.Louis, Apt.4, Boucherville.\u2014 An emplacement located in Dunany, County of Argenteuil forming part of original lot number one, letter \"B\", in Third Range, Township of Gore, County of Argenteuil Registration Division, (Pt.IB, R.UI); Bounded on the southwest by a proposed street forty feet (40') in width, forming part of said lot 1-B, Range UI (l-B-2, R.UI, proposed), on the southeast side by another proposed street forty feet (40') in width, forming part of said lot 1-B, Range IU, (l-B-6, Rg.IU, proposed), and on all other sides by non subdivided parts of said lot 1-B, Range UI, Township of Gore; Measuring one hundred feet (100') in width on its northwest and southeast lines by a depth of one hundred feet (100') on its northeast and southwest lines, covering an area of ten thousand square feet (10,000 sq.ft.), English measure, more or less; The southeast line of said emplacement is parallel to the dividing line between Ranges 1-A and 1-B, Range IU, Township of Gore, and is located at a distance of eight hundred twenty feet (820') to the southeast of the latter; The southwest line of said emplacement is perpendicular to the dividing line between lots 1-A and 1-B, Range HI, in said Township of Gore, and is located at a distance of one thousand six hundred ninety-one feet (1,691') from the dividing line between Ranges U and UI in said Township; such distance being measured along the dividing line between lots 1-A and 1-B in said Township, in a southwesterly direction; This emplacement bears number sixty-six and sixty-seven (Nos.66 and 67) on a proposed subdivision plan.Municipal taxes: $54.78. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 2043 Robert Turnbull, 95, Sunshine Dr., Dollard-des-Ormeaux.\u2014 Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore comme étant le lot numéro trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro neuf, lettre « B », dans le sixième rang (9B-3, rg 6); à distraire dudit terrain une bande de terre de dix pieds (10') de largeur sur toute la profondeur dudit lot, ladite bande de terre ayant été vendue à dame Jane Ann Chapman, épouse de Thomas G.Sowerby, par un acte enregistré sous le numéro 68197; avec tous les bâtiments y érigés.Tel que le tout se trouve actuellement avec toutes les servitudes pouvant s'y rattacher et tout particulièrement un droit de passage sur le lot numéro cinquante-deux dudit lot originaire numéro neuf B dans le sixième rang, servitude accordée suivant les titres de propriété du vendeur.Taxes municipales: $136.23.Romas Verbyla, 5974, Turenne, Montréal.\u2014 Un emplacement situé à Lakefield, comté d'Argenteuil, connu et désigne comme étant une partie du lot onze, lettre A, rang quatre (ptie 11 A, rg IV) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Gore; Ledit terrain étant de forme irrégulière et ayant front sur la rue 11A-55, mesurant soixante-quinze pieds (75') en frontdans sa ligne sud-ouest, cent vingt-trois pieds (123') dans sa ligne sud-est, cette dernière étant une ligne irrégulière, soixante pieds (60') à l'arrière dans sa ligne nord-est et environ cent huit pieds (108') dans sa ligne nord-ouest; Borné en front au sud-ouest par ladite rue ll-A-55, à l'arrière et sur les autres côtés par d'autres parties dudit lot 11A; Les premiers soixante-trois pieds (63') de la ligne sud-est dudit terrain sont situés à une distance de cent dix-sept pieds (117') à l'ouest du chemin public et à partir de là ladite ligne est située à cent pieds (100') du chemin public jusqu'au point où elle rencontre la ligne nord-est; La ligne nord-est dudit emplacement est perpendiculaire au chemin public et commence à une distance de cent pieds (100') du chemin public; Tel que le tout se trouve actuellement avec toutes les servitudes y rattachées.Taxes municipales: $219.94.Wolfgang Scheillberger, B.P.292, St-Adèle-en-Bas, (Que.).- Partie des lots Nos 12B, 13, rang V, canton de Gore.1.Un certain terrain faisant partie du lot No 12B dans le cinquième rang du canton de Gore, comté d'Argenteuil, mesurant 9.85' de largeur du côté du lac Bird sur 285' de profondeur, borné au nord par le lac Bird, à l'est par le lot No 13, à l'ouest et au sud par partie du lot No 12B, propriété du vendeur.2° Un certain terrain faisant partie du lot No 13 dans le cinquième rang du canton de Gore, comté d'Argenteuil, mesurant 120' de largeur du côté du lac Bird, sur 300' de profondeur.Borné au nord par le lac Bird, à l'ouest par la ligne de division entre les lots Nos 12B et 13, à l'est (232' et 75') et au sud (80' et 40') par les propriétés de M.J.C.Dalgleish, M.J.Yapety et Ott & Company Inc.ou de leurs successeurs.Robert Turnbull, 95 Sunshine Dr., Dollard des Ormeaux.\u2014 A certain piece of land known and designated on the official plan and in the book of reference of the Township of Gore, as being the lot number Three of the official subdivision of the original lot number nine letter \"B\", in the sixth range (9B-3, R.6) to be deducted therefrom a strip of land of ten feet (10') wide by the depth of said lot, which strip of land was sold to Dame Jane Ann Chapman, wife of Thomas G.Sowerby, by deed registered under the number 68197; with all the buildings thereon erected.As the whole now subsists with all the servitudes which may be attached thereto and specially a right-of-way on the lot number fifty-two of the said original lot number nine B in the sixth range as granted on the title deed of the vendor.Municipal taxes: $136.23.Romas Verbyla, 5974 Turenne, Montreal.\u2014 An emplacement at Lakefield, County of Argenteuil, known and designated as being a Part of lot eleven letter \"A\", Range four (Pt.11A, Rg.IV) on the official plan and book of reference for the Township of Gore; Of irregular form fronting on street 11A-55, measuring seventy-five feet (75') in front in its southwest line, one hundred and twenty-three feet (123') in its southeast line, which is a broken line, sixty feet (60') in rear in its northeast line, and about one hundred and eight feet (108') in its northwest line; Bounded in front to the southwest, by said street ll-A-55, in rear and on the other sides, by other parts of said lotllA; The southeast line of the said emplacement in its first sixty-three feet (63') is situated at one hundred and seventeen feet (117') to the west of the Public Road and from there it goes at one hundred feet (100') from the said Public Road, at its Meeting point with the northeast line; The northeast line of the said emplacement is perpendicular to the said Public road and starts at one hundred feet (100') from the said Public Road; As the whole now subsists with all the servitudes attached thereto.Municipal taxes: $219.94.Wolfgang Scheillberger, Box 292, St.Adèle-en-Bas, Que.\u2014 Part Lot Nos.12B, 13, Range V, Township of Gore.(1) A certain piece of land forming part of Lot No.12B in the Fifth Range of the Township of Gore, County of Argenteuil, measuring 9.85' wide on Bird Lake by 285' in depth, bound on the north by Bird Lake, east by Lot No.13, west and south by part Lot No.12B property of the vendor.(2) A certain piece of land forming part of Lot No.13 in the Fifth Range of the Township of Gore, County of Argenteuil, measuring 120' wide on Bird Lake by a depth of 300'.Bound on the north by Bird Lake, west by the dividing line between Lot Nos.12B and 13, east (232' and 75') and south (80' and 40') by the properties of Mr.J.C.Dalgleish, Mr.J.Yapety and Ott & Company Inc., or their successors. 2044 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March S, 1974, Vol.106, No.10 Avec une servitude de passage conduisant aux lacs Bird et Barron, sans bâtisses y érigées.A distraire la moitié indivise (50%) vendue à François Charlebois, acte No 123610.Taxes municipales: $45.59.Corporation municipale du canton de Grenville et augmentation Télesphore Poulin, Grenville, Que.\u2014 La moitié ouest du lot tel que désigné au cadastre officiel du canton de Grenville comme étant le lot 25, lettre B dans le rang 4, contient environ 50 acres en superficie.C'est le lot appartenant anciennement à Victor D'Aoust.Taxes municipales: $11.50.Corporation municipale du canton de Harrington John McDougall, adresse inconnue.\u2014 Un emplacement situé dans le canton de Harrington, connu et désigné sous le numéro vingt-cinq de la subdivision du lot originaire numéro quatorze C (14C-25) du cinquième rang, aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Harrington, comté d'Argenteuil, couvrant une superficie de dix mille six pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, avec le bâtiment dessus érigé.Tel que le tout existe présentement avec tous ses droits, membres et circonstances et particulièrement un droit de passage à pied et en voitures de tous genres, afin d'avoir accès à la grève et au lac, ladite servitude ayant été créée par un acte de vente enregistré à Argenteuil sous le numéro 111673.Taxes municipales: $99.43.Ronald Manson, 250, 10c Avenue, Deux-Montagnes.Un emplacement connu et désigné comme étant une partie du lot originaire numéro sept, lettre B, dans le septième rang (ptie 7B.rg 7) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Harrington, comté d'Argenteuil.Mesurant cent vingt-deux pieds (122') dans sa ligne sud, environ quatre-vingt-douze pieds (92') dans sa ligne nord-ouest et environ cent soixante-cinq pieds (165') dans sa ligne nord-est et quatre-vingt-dix pieds (90') dans sa ligne sud-ouest et ayant une superficie de 11,000 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins.Borné au sud par la rue 7B-17, dudit rang, dudit cadastre.Au nord-ouest et au sud-ouest par d'autres parties dudit lot 7B, et au nord-est en partie par un emplacement appartenant à Edward Murphy et en partie par une autre partie dudit lot 7B.Sa ligne nord-est rejoint larue 7B-17 à un point situé à une distance de cent pieds (100') de la ligne nord de ladite rue 7B-17.Et la prolongation de sa ligne nord-est rejoint la nie 7B-25, dudit rang, dudit cadastre, à une distance de deux cent soixante-huit pieds (268') de la ligne de division entre les rues 7B-25 et 7B-26.Ledit emplacement apparaît également comme étant le lot 101B sur un plan de subdivision projetée connu du comparant.Avec une maison dessus construite.Taxes municipales: $205.66.With right of way to Bird and Barron Lakes, with no buildings thereon.Less the undivided half (50%) sold to François Charlebois.Deed No.123610.Municipal taxes: $45.59.Municipal Corporation of the Township of Grenville and augmentation Télesphore Poulin, Grenville, P.Q.\u2014 The west half of lot as described on the official cadastre for the Township of Grenville as being lot 25, letter B in Range 4, and covering an area of 50 acres.Said lot was previously owned by Victor d'Aoust.Municipal taxes: $11.50.Municipal Corporation of the Township of Harrington John McDougall, unknown address.\u2014 An emplacement situated in the Township of Harrington, known and designated under number twenty-five of the subdivision of the original lot number fourteen C (14C-25) of the Fifth Range upon the plan and book of reference of said Township of Harrington County of Argenteuil, having a superficial area of ten thousand six square feet, English measure and more or less, with the building thereon erected.As the whole now subsists with all its rights, members and appurtenances and specially with the right of passage by foot and vehicles of all sorts to have access on the beach and to the lake as created in the deed of sale registered at Argenteuil under number 111673.Municipal taxes: $99.43.Ronald Manson, 250 - 10th Ave., Two Mountains.\u2014 An emplacement known and designated as being a Part of the original lot seven letter B, in the Seventh Range (Pt.7B, Rg.VU) on the official plan and book of reference of the Township of Harrington, County of Argenteuil.Measuring one hundred and twenty-two feet (122') in its south line, about ninety-two (92') in its north west line and about one hundred and sixty-five feet (165') in its northeast line and ninety feet (90') in its southwest line and having a superficial area of 11,000 square feet English measure and more or less; Bounded to the south by the street 7B-17 said range, said cadastre.To the northwest and to the southwest by other parts of said lot 7B, and to the northeast partly by an emplacementbelonging to Edward Murphy and partly by another part of said lot 7B.Its northeast line reaches the street 7B-17 at a point situated at one hundred feet (100') from the north line of the said street 7B-17.And the continuation of its northeast line reaches the street 7B-25, said range, said cadastre at two hundred and sixty eight feet (268') from the Division line between the streets 7B-25 and 7B-26.Said emplacement appearing also as lot 101B on a proposed subdivision plan known to the appearer.With a house thereon erected.Municipal taxes: $205.66. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 197J,, 106' année, n\" 10 2045 Gordon Doherty, Case postale 508, Ottawa (Ont.).\u2014 Un terrain vague situé dans le canton de Harrington, comté d'Argenteuil, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Harrington comme étant le lot numéro quatre-vingt-dix-sept du lot originaire numéro quinze (15-97) dans le cinquième rang, et ayant une superficie totale de trente et un mille deux cent quatre-vingt-treize pieds carrés (31,293'), le tout en mesure anglaise et plus ou moins.Tel que le tout existe présentement avec tous ses ses droits, membres et circonstances sans exception ni réservation d'aucune sorte de la part du vendeur.Taxes municipales: $28.85.Lawrence Dore, adresse inconnue.\u2014 Un terrain vague situé dans le canton de Harrington, comté d'Argenteuil, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels dudit enton de Harrington comme étant le lot numéro trois du lot originaire numéro quatorze lettre C (14C-3) dans le cinquième rang, et ayant une superficie totale de treize mille six cent cinquante pieds carrés (13,650'), le tout en mesure anglaise et plus ou moins.Tel que le tout existe présentement avec tous ses droits, membres et circonstances sans exception ni réservation d'aucune sorte de la part du vendeur.Taxes municipales: $19.57.Succession A.Roy Durocher, adresse inconnue.\u2014 Un terrain vague situé dans le canton de Harrington, comté d'Argenteuil, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Harrington comme étant le lot numéro soixante-six et soixante-trois du lot originaire numéro quatorze lettre C dans le cinquième rang, et ayant une superficie totale de quatorze mille pieds carrés (14,000') le tout en mesure anglaise, et plus ou moins.Tel que le tout existe présentement avec tous ses droits, membres et circonstances sans exception ni réservation de la part du vendeur.Taxes municipales: $24.62.Maurice Grenier, 2480, Benny Crescent app.207, Montréal, (Que.).\u2014 Un terrain vacant situé dans le canton de Harrington, comté d'Argenteuil, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton comme étant le lot numéro soixante-seize de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatorze C (14C-76) dans le cinquième rang et ayant une superficie totale de soixante-dix mille deux cent dix pieds carrés (70,210 p.c), le tout en mesure anglaise et plus ou moins.Le tout tel qu'il existe, avec tous ses droits, membres et circonstances sans exception ni réserve d'aucune sorte de la part du vendeur.Taxes municipales: $116-84 ; taxes scolaires: $222.12.Total: $338.96.Girolamo Giorgi, 1426, Thierry, LaSalle, (Que.).\u2014 Un emplacement situé dans le canton de Harrington, dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Harrington comme étant le lot numéro quatre-vingt-quatre du lot originaire numéro quatorze, lettre « C » (14C-84) dans le cinquième rang et ayant une superficie totale dc Gordon Doherty, Box 508, Ottawa, Ont.\u2014 A vacant piece of land situated in the Township of Harrington, in the County of Argenteuil known and designated on the official plan and book of reference of the said Township of Harrington as being lot number ninety-seven of the original lot number fifteen (15-97) in the Fifth Range, and having a total superficial area of thirty-one thousand two hundred and ninety-three square feet (31,293') the whole English measure and more or less.As the whole now subsists with all its rights, members and appurtenances without exception or reserve of any kind on the part of the vendor.Municipal taxes: $28.85.Lawrence Dore, unknown address.\u2014 A vacant piece of land situated in the Township of Harrington, in the County of Argenteuil known and designated on the official plan and book of reference of the said Township of Harrington as being lot number three of the original lot number fourteen letter C (14C-3) in the Fifth Range, and having a total superficial area of thirteen thousand six hundred and fifty square feet (13,650') the whole English measure and more or less.As the whole now subsists with all its rights, members and appurtenances without exception or reserve of any kind on the part of the vendor.Municipal taxes: $19.57.Estate A.Roy Durocher, unknown address.\u2014 A vacant piece of land situated in the Township of Harrington, in the County of Argenteuil known and designated on the official plan and book of reference of the said Township of Harrington as being lot number sixty-six and sixty-three of the original lot number fourteen letter C in the Fifth Range, and having a total superficial area of fourteen thousand square feet (14,000') the whole English measure and more or less.As the whole now subsists with all its rights, members and appurtenances without exception or reserve of any kind on the part of the vendor.Municipal taxes: $24.62.Maurice Grenier, 2480 Benny Crescent, Apt.207, Montreal, Que.\u2014 A vacant piece of land situated in the Township of Harrington, in the County of Argenteuil, known and designated on the official plan and book of reference of the said Township of Harrington as being lot number seventy-six of the official subdivision of the original lot number fourteen C (14C-76) in the Fifth Range, and having a total superficial area of seventy thousand two hundred and ten square feet (70,210 sq.ft), the whole English measure and more or Jess.As the whole now subsists, with all its rights, members and appurtenances without exception or reserve of any kind on the part of the vendor.Municipal taxes: $116.84; school taxes: $222.12.Total: $338.96.Girolamo Giorgi, 1426 Thierry, LaSalle, Que.\u2014 An emplacement situated in the Township of Harrington, in the County of Argenteuil, known and designated on the official plan and book of reference of the said Township of Harrington as being lot number eightv-four of the original lot number fourteen letter \"C\" (14C-84) in the Fifth Range, and having a total 2046 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol- 106, No.10 soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix pieds carrés (74,490 p.c), le tout en mesure anglaise, et plus ou moins.Taxes municipales: $122.74.Reginald Pomposelli, adresse inconnue.\u2014 Une parcelle de terrain dans le canton de Harrington, comté d'Argenteuil, province de Québec, ayant front sur l'avenue Pineview, connue comme étant une partie non subdivisée du lot treize B (ptie 13B) dans le neuvième rang aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Harrington, mesurant cent quarante-six pieds huit dixièmes dans sa ligne sud-ouest, environ trente-cinq pieds dans sa ligne sud-est, environ cent cinq pieds dans sa ligne est, environ cinquante-quatre pieds dans sa ligne nord-est et cent pieds dans sa ligne nord-ouest, borné au sud-ouest par une rue étant la subdivision quarante-huit dudit lot, au sud-est par une autre rue étant la subdivision quarante-quatre dudit lot, à l'est par une autre rue étant la subdivision quarante-cinq dudit lot, au nord-est par une autre partie dudit lot treize B (étant le numéro non-officiel cent soixante-quinze au plan ci-après mentionne) et au nord-ouest par une autre partie dudit lot 13B (étant le numéro non-officiel cent soixante-sept audit plan).La ligne nord-est dudit terrain est parallèle à la ligne de ladite subdivision quarante-huit et située à une distance de cent pieds de celle-ci.Toutes les mesures ci-dessus mentionnées sont en mesures anglaise et plus ou moins.Ladite parcelle de terrain est désignée comme étant les numéros non-officiels cent soixante-cinq et cent soixante-six sur un plan préparé par Maurice Gau-dreault, arpenteur-géomètre, en date du sept juillet, mil neuf cent cinquante-neuf et revisé le vingt-six avril, mil neuf cent soixante.Sous réserve de la servitude ou des servitudes en faveur de la compagnie de Téléphone Bell du Canada et de la compagnie Gatineau Power.Tel que ladite propriété se trouve présentement avec tous ses droits, membres et circonstances sans exception ni réservation d'aucune sorte de la part du vendeur.Taxes municipales: $156.18.Mme Robert Edwards.\u2014 Un emplacement vacant à Lost River, comté d'Argenteuil, connu et désigné comme faisant partie du lot trois, lettre « A » dans le quatrième rang (ptie 3A, rg IV) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Harrington ; Mesurant cent pieds de largeur (100') dans ses lignes nord-ouest et sud-est, sur cent soixante-quinze (.ieds (175') de profondeur, ayant une superficie de 17,500 pieds carrés, le tout en mesure anglaise et plus ou moins; Borné au nord-ouest par un chemin privé, sur un côté au nord-est par une autre partie dudit lot 3A, appartenant à J.M.Robert, de l'autre côté au sud-ouest par une autre partie dudit lot 3A, appartenant à A.Kapunta, et à l'arrière au sud-est par une autre partie dudit lot 3A, propriété de Freda Gallant-Batten.superficial area of seventy-four thousand four hundred and ninety square feet (74,490 sq.ft.) the whole, English measure and more or less.Municipal taxes: $122.74.Reginald Pomposelli, unknown address.\u2014 A parcel of land in the Township of Harrington in the County of Argenteuil in the Province of Québec, fronting on Pineview Avenue, known as and unsubdivi-ded part of lot thirteen B (Pt.13B) in the Ninth Range on the official plan and book of reference of the Township of Harrington measuring one hundred and forty-six feet and eight-tenths of a foot in its southwest line, approximately thirty-five feet in its southeast line, approximately one hundred and five feet in its east line, approximately fifty-four feet in its northeast line and one hundred feet in its northwest line, bounded to the southwest by a Street being subdivision forty-eight of the said lot,\" to the southeast by another Street being subdivision forty-four of the said lot, to the east by another Street being subdivision forty-five of the said lot, to the northeast by another part of the said lot thirteen B (being unofficial number one hundred and seventy-five on the plan hereinafter referred to) and to the northwest by another part of the said lot thirteen B (being unofficial number one hundred and sixty-seven on the said plan).The northeast line of the said parcel of land is parellel to and one hundred feet from the northeast line of the said subdivision forty-eight.All the above measurements are English measure and more or less.The said parcel of land is shown as unofficial numbers one hundred and sixty-five and one hundred and sixty-six on a plan prepared by Maurice Gaudreault, Québec Land Surveyor, dated the seventh day of July nineteen hundred and fifty-nine and revised on the twenty-sixth day of April nineteen hundred and sixty.Subject to the servitude or servitudes in favour of The Bell Telephone Company of Canada and The Gatineau Power Company.As the said property now subsists with all its rights, members and appurtenances without exception or reserve of any kind on the part of the vendor.Municipal taxes: $156.18.Mrs.Robert Edwards.\u2014 A vacant emplacement at Lost River, Co.of Argenteuil, known and designated as being part of lot three letter \"A\", in the Fourth Range (Pt.3A, Rg.IV) on the official plan and book of reference of the Township of Harrington ; Measuring one hundred feet (100') in width in its northwest and southeast lines by one hundred and seventy-five feet (175') in depth in having a superficial area of 17,500 square feet, the whole English measure and more or less; Bounded to the northwest by a private road, on one side to the northeast by another part of said lot 3A, belonging to J.M.Robert, on the other side to the southwest by another part of said lot 3A, belonging to A.Kapunta, and in rear to the southeast by another part of said lot 3A, belonging to Freda Gallant-Batten. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n' 10 2047 Ledit emDlacement est connu comme étant le lot 90 sur un plan de subdivision projetée préparé par André Ladouceur, arpenteur-géomètre, le 30 juin 1960 et revisé le 5 juillet 1960.Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes y rattachées, et tout particulièrement une servitude en faveur de la compagnie de Téléphone Bell du Canada ou de la compagnie Gatineau Power.Taxes municipales: $41.66.James Robert Ryan, 1073, Prud'homme, Montréal.\u2014 Un terrain situé dans le canton de Harrington, comté d'Argenteuil, comprenant les subdivisions trente et un et trente-deux du lot originaire numéro onze « B » (11B-31 et 32) dans le neuvième rang aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton; ledit terrain étant de forme irrégulière et borné en front, au sud-ouest par le lac Vert (Green Lake) à l'arrière, au nord-est, par le chemin public, d'un côté, au nord-ouesl, par le lot numéro llB-30, et de l'autre côté, au sud-est, par le lot numéro 11B-33, lesdites subdivisions ayant des superficies respectives dc huit mille six cent soixante-quinze pieds carrés (8,675 p.c.) et neuf mille cinq cent vingt pieds carrés (9,520 p.c), mesures anglaises et plus ou moins.Avec une maison y érigée.Tel que la propriété se trouve présentement, avec tous ses droits, membres et circonstances, sous réserve de toutes les servitudes actives et passives y rattchées, sans exception ni réserve d'aucune sorte de la part du vendeur.Taxes municipales: $129.72.Dimitrios Salivaras, adresse inconnue.\u2014 Un terrain vague situé dans le canton de Harrington, dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Harrington comme étant le lot numéro cinquante-sept du lot originaire numéro quinze (15-57) dans le cinquième rang, et ayant une surface totale de quinze mille sept cent quatre-vingt-huit pieds carrés (15,788 p.c), le tout en mesures anglaises, plus ou moins.Le tout tel qu'il se trouve actuellement avec tous ses droits, membres et circonstances, sans exception ou réserve d'aucune sorte de la part du vendeur.Taxes municipales: $28.85.Amélie F.Willems, 2750, Bedford Road, app.94, Montréal.\u2014 Un terrain vague situé dans le canton de Harrington, dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Harrington, comme étant le lot numéro dix-huit du lot originaire numéro quinze (15-18) dans le cinquième rang, et ayant une surface totale de quinze mille sept cent pieds carrés (15,700 p.c), mesures anglaises, plus ou moins.Le tout tel qu'il se trouve actuellement, avec tous ses droits, membres et circonstances, sans exception ou réserve d'aucune sorte de la part du vendeur.Taxes municipales: $87.70.Kenneth B.Seary, adresse inconnue.\u2014 Un terrain vague situé dans le canton de Harrington, dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné aux plan Said emplacement appearing as lot 90, on a proposed subdivision plan prepared by André Ladouceur, Land Surveyor, on the 30th of June 1960, revised on the 5th of July 1960.As the whole now subsists with all the servitudes attached thereto, and especially subject to any servitude in favor of the Bell Telephone Co.or the Gatineau Power.Municipal taxes: $41.66.James Robert Ryan, 1073 Prud'homme, Montreal \u2014 An emplacement situated in the Township of Harrington, County of Argenteuil, composed of subdivisions thirty-one and thirty-two of the original lot number eleven \"B\" (11B-31 and 32) in the Ninth Range on the official plan and book of reference of said Township, being of irregular figure and bounded in front to the southwest by Lac Vert (Green Lake), in rear to the northeast by the Public Road, on one side to the northwest by lot number IIB-30, and on the other side to the southeast by lot number IIB-33, the said subdivisions containing areas of eight thousand six hundred and seventy-five (8,675) square feet and nine thousand five hundred and twenty (9,520) square feet, respectively, English measure and more or less.With a house thereon erected.As the said property now subsists, with all its rights, members and appurtenances, subject to all servitudes active and passive thereto attached, without exception or reserve of any kind on the part of the vendor.Municipal taxes: $129.72.Dimitrios Salivaras, unknown address.\u2014 A vacant piece of land situated in the Township of Harrington, in the County of Argenteuil, known and designated on the official plan and book of reference of the said Township of Harrington as being lot number fifty-seven of the original lot number fifteen (15-57) in the Fifth Range, and having a total superficial area of fifteen thousand seven hundred and eighty-eight square feet (15,788' sq.ft.) the whole English measure and more or less.As the whole now subsists with all its rights, members and appurtenances without exception or reserve of any kind on the part of the vendor.Municipal taxes: $28.85.Amélie F.Willems, 2750 Bedford Road, Apt.94, Montreal.\u2014 A vacant piece of land situated in the Township of Harrington, in the County of Argenteuil, known and designated on the official plan and book of reference of the said Township of Harrington, as being lot number eighteen of the original lot number fifteen (15-18) in the Fifth Range, and having a total superficial area of fifteen thousand and seven hundred square feet (15,700 sq.ft.), English measure and more or less.As the whole now subsists, with all its rights, members and appurtenances, without exception of reserve of any kind on the part of the vendor.Municipal taxes: $87.70.Kenneth B.Seary, unknown address.\u2014 A vacant piece of land situated in the Township of Harrington, in the County of Argenteuil, known and 2048 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol- 106, No.10 et livre de renvoi officiels dudit canton de Harrington comme étant les lots numéros trente-six, trente-neuf et quarante-trois du lot originaire numéro quatorze C dans le cinquième rang, et ayant respectivement des surfaces totales de 16,103 p.c.(lot 36), 20,334 p.c.(lot 39) et 14,000 p.c.(lot 43), le tout mesures anglaises, plus ou moins.Le tout tel qu'il se trouve actuellement avec tous ses droits, membres et circonstances sans exception ou réserve d'aucune sorte.Taxes municipales: $73.65.Howard W.White, 530, 62e Ave, Laval.\u2014 Un emplacement composé des lots soixante-quatorze, soixante-quinze et soixante-seize de la subdivision officielle du lot originaire treize B (13B-74, 75, 76) du neuvième rang aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Harrington, comté d'Argenteuil.Taxes municipales: $154.76.Alphonse Guimond, 282 Pine Ave Est, Montréal.\u2014 Un emplacement vacant à Lost River, comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant une partie du lot quatre lettre « B », dans le rang quatre (ptie 4B, rg IV) aux plan et livre de renvoi officiels du canton Harrington; Mesurant cent pieds (100') de largeur dans ses lignes sud-est et nord-ouest, par cent quatre-vingt pieds (180') de profondeur, dans ses lignes nord-est et sud-ouest, mesure anglaise et plus ou moins; Bornée en front au sud-est, par un chemin privé, en arrière et des deux côtés par d'autres parties dudit lot4B; Cet immeuble apparaît comme le lot 114 sur un projet de subdivision non déposé préparé par André Ladouceur, a.g.en date du 30 juin 1960, revisé le 5 juillet 1960.Ainsi que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes y attachées, et sujet à toutes servitudes qui peuvent exister en faveur de The Bell Telephone Co.ou The Gatineau Power.Taxes municipales: $20.15.Constant Mechas, adresse inconnue.\u2014 Un terrain vacant situé dans le canton de Harrington, comté d'Argenteuil, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Harrington comme étant le lot numéro quatre-vingt-un du lot originaire numéro quinze (15-81) dans le cinquième rang, et ayant une superficie totale de quatorze mille sept cent pieds carrés (14,700 p.c), le tout en mesure anglaise, plus ou moins.Taxes municipales: $28.85.Corporation municipale du Village de Saint-André Est Mlle Georgette Ladouceur, 439 rue Lafk-ur.Lachute, Que.\u2014 Un certain emplacement situé au village de St-André d'Argenteuil, faisant partie du lot numéro quatre cent deux (ptie 402) aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Saint-André d'Argenteuil mesurant quarante-deux pieds et six pouces (42'6\") de largeur, sur cent soixante pieds (160') de profondeur, mesures anglaises et plus ou moins, borné en front, au sud par la designated on the official plan and book of reference of the said Township of Harrington as being lots numbers thirty-six, thirty-nine and forty-three of the original lot number fourteen C in the Fifth Range, and having a total superficial area of respectively of 16,103 (Lot 36) 20,334 (Lot 39), 14.000 (Lot 43) the whole English measure and more or less.As the whole now subsists with all its rights members and appurtenances without exception of reserve of any kind.Municipal taxes: $73.65.Howard W.White, 530 - 62nd Ave., Laval.\u2014 An emplacement composed of lots seventy-four seventy-five and seventy-six of the official subdivision of original thirteen B (13B-74, 75, 76) of the Ninth Range (Rg.IX) on the official plan and book of reference of the Township of Harrington, County of Argenteuil.Municipal taxes: $154.76.Alphonse Guimond, 282 Pine Ave.East, Montreal.A vacant emplacement in Lost River, Argenteuil County, known and described as being part of lot four letter « B », in Range Four (Pt.4B, Rg.TV) on the official plan and book of reference for the Township of Harrington ; Measuring one hundred feet (100') in width on its southeast and northwest lines, by one hundred eighty feet (180') in depth on its northeast and southwest lines, English measure, more or less; Bounded in front on the southeast, by a private road, in the back and on both sides by other parts of said lot 4B; This immoveable appears as lot 114 on an unfiled subdivision project prepared by André Ladouceur, q.L.s., dated June 30, 1960, revised on July 5, 1960.As the whole now subsists with all the servitudes attaching thereto, and subject to all servitudes which may exist in favour of to The Bell Telephone Co.or The Gatineau Power.Municipal taxes: $20.15.Constant Mechas, unknown address.\u2014 A vacant piece of land situated in the Township of Harrington, in the County of Argenteuil known and designated on the official plan and book of reference of the said Township of Harrington as being lot number eighty-one of the original lot number fifteen (15-81) in the Fifth Range, and having a total superficial area of fourteen thousand seven hundred square feet (14,700) the whole English measure and more or less.Municipal taxes: $28.85.Municipal Corporation of the Village of St.André East Miss Georgette Ladouceur, 439 Lafleur Street, La-chute, Que.A certain emplacement located in the Village of St.André d'Argenteuil, forming part of lot number four hundred two (Pt.402) on the official plan and in the book of reference for the Parish of St.André d'Argenteuil measuring forty-two feet and six inches (42'6\") in width by a depth of one hundred sixty feet (160'), English measure and more or less, bounded in front on GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n' 10 2049 rue de l'École, en arrière au nord par partie du lot 402 appartenant à Maurice Legault ou représentants à l'ouest par partie du même lot appartenant à Jean Baptiste Ladouceur ou représentants et à l'est par partie du même lot appartenant à la succession John Ladouceur ou représentants.Le tout avec bâtisses dessus érigées.Taxes municipales: $5.04; taxes scolaires: $7.04.Total: $12.08.St.Andrews Marina Entreprises (Social Club), St-André Est.\u2014 Un certain emplacement connu et désigné au plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-André, comme étant le lot numéro quatre cent trente-quatre (434) déduction faite de la partie dudit lot vendue à Donat Fournier par acte enregistré sous le numéro 67341, avec les bâtisses y érigées, tous les droits, circonstances et dépendances ainsi que toutes les servitudes y attachées.Taxes municipales: $510.71 ; taxes scolaires: $348.50.Total: $859.21.Municipalité de Mille-lsles Bertrand Dion, adresse inconnue.\u2014 Lot No 7-18; 7-19.Un certain terrain connu et désigné comme étant les lots numéros dix-huit et dix-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept (7) dans le rang Côte Saint-Joseph E.aux plan et livre de renvoi officiels de la municipalité de Mille-lsles.Numéro d'enregistrement 118814.Taxes municipales: $10.89; taxes scolaires: $11.43.Total: $22.32.Jacques Ouellette, adresse inconnue.\u2014 Lot No 7-89.Un certain terrain connu et désigné comme étant le lot numéro quatre-vingt-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept (7; dans le rang Côte Saint-Joseph E.aux plan et livre de renvoi officiels d; la municipalité de Mille-lsles.Taxes municipales: $8.57; taxes scolaires: $11.71.Total: $20.28.Roland Diamond (par fidéicommis), 3500, Henri-Bourassa, Montréal.\u2014 Lot numéro 7-93.Un certain terrain connu et désigné comme étant le lot numéro quatre-vingt-treize (93) de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept (7) du rang Côte-Saint-Joseph E.aux plan et livre de renvoi officiels de la municipalité de Mille-lsles.Taxes municipales: $4.83; taxes scolaires: $8.60.Total: $13.43.Municipalité de la paroisse de St-André-Est Bernard Bresilley, 1280 St-Marc, app.902, Montréal.\u2014 Différents emplacements vacants situés à St-André-d'Argenteuil, comté d'Argenteuil, et décrits comme suit, savoir: 1.Une partie du lot originaire numéro sept cent trente-trois (ptie 733) au cadastre de la paroisse St-André-d'Argenteuil, de forme rectangulaire mesurant cent soixante-quinze pieds (175') de largeur dans ses lignes est et ouest, par cent pieds (100') de profondeur, le tout mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: en front, vers l'est, par une rue the south by Rue de l'École, at the rear on the north by a part of lot 402 belonging to Maurice Legault or representatives, on the west by a part of same lot belonging to Jean-Baptiste Ladouceur or representatives and on the east by a part of same lot belonging to the estate of John Ladouceur or representatives.The whole with the buildings erected thereon.Municipal taxes: $5.04; school taxes: $7.04.Total: $12.08.St.Andrews Marina Entreprises, (Social Club), St.André Est.A certain emplacement known and described on the official plan and in the book of reference for the Parish of St.André, as being lot number four hundred thirty-four (434), less and to withdraw that part of said lot sold to Donat Fournier by a deed registered under number 67341, with the buildings erected thereon, all the rights, appurtenances and dependencies and all servitudes attaching thereto.Municipal taxes: $510.71; school taxes: $348.50.Total: $859.21.Municipality of Mille-lsles Bertrand Dion, unknown address.\u2014 Lot No.7-18; 7-19.A certain piece of land known and designated as being lot numbers eighteen and nineteen of the official subdivision of the original lot number seven (7) in Range Côte St.Joseph of the Municipality of Mille-lsles.Reg.No.: 118814.Municipal taxes: $10.89; school taxes $11.43.Total: $22.32.Jacques Ouellette, unknown address.\u2014 Lot No.7-89.A certain piece of land known and designated as being lot number eighty-nine, of the official subdivision of the original lot number seven (7) in range Côte St.Joseph E.upon the official plan and book of reference of the Municipality of Mille-lsles.Municipal taxes: $8.57; school texes:$11.71.Total: $20.28.Roland Diamond, (In Trust), 3500 Henri Bourassa, Montreal.\u2014 Lot No.7-93.A certain piece of land known and designated as being lot number ninety-three (93) of the official subdivision of the original lot number seven (7) on range Côte St.Joseph E.upon the official plan and book of reference of the Municipality of Mille-lsles.Municipal taxes: $4.83; school taxes: $8.60.Total: $13.43.Municipality of the Parish of St.Andrews East Bernard Bresilley, 1280 St.Marc, Apt.902, Montreal.\u2014 Various vacant emplacement located in St.André-d'Argenteuil, County of Argenteuil, and described as follows, to wit: 1.A part of original lot number seven hundred thirty-three (Pt.733) on the cadastre of the Parish of St.André-d'Argenteuil, of rectangular configuration measuring one hundred seventy-five feet (175') in width on its east and west lines, by a depth of one hundred feet (100'), the whole in English measure and more or less and bounded as follows: in front, towards the 2050 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9.1974, Vol.106, No.10 projetée et privée appelée avenue Tour du Lac et étant une partie dudit lot No 733; en arrière, vers l'ouest, par une rue projetée étant aussi une partie du lot No 733; vers le nord, par une autre partie dudit lot No 733 appartenant à Jean-Guy Lévesque, suivant acte enregistré sous le No 122605; et, de l'autre côté, vers le sud, par une autre partie dudit lot No 733 appartenant au vendeur; la ligne sud de l'emplacement ci-dessus décrit est parallèle à et située à cent dix pieds ( 110') de la ligne nord du lot No 734 et la ligne ouest de l'emplacement présentement vendu est parallèle à et située à environ cent cinquante pieds (150') de la ligne est du lot No 736, tous du même cadastre.2.Une partie du lot originaire numéro sept cent trente-six (ptie 736) au cadastre de la paroisse St-André-d'Argenteuil, de forme carrée, mesurant deux cents pieds (200') de largeur par deux cents pieds (200') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: vers le nord par une partie dudit lot No 733 étant une rue projetée; vers l'est, par une partie du lot No 733 étant une rue projetée; vers le sud et l'ouest par d'autres parties dudit lot No 733 appartenant au vendeur, la ligne sud dudit emplacement est parallèle à et située à quatre cent quarante pieds (440') de la ligne nord du lot No 735 du même cadastre, et la ligne est dudit emplacement est parallèle à et située à cent quarante pieds (140') de la ligne est du lot No 736, du même cadastre.3.Une partie du lot originaire numéro sept cent trente-six (ptie 736) au cadastre de la paroisse St-André-d'Argenteuil, de forme rectangulaire, mesurant cent pieds (100') de largeur par deux cents pieds (200') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: vers le sud, par une partie du lot No 733 étant une rue projetée; vers l'est, par une partie dudit lot No 733 étant une rue projeté vers le nord et vers l'ouest par d'autres parties dudit lot No 733 appartenant au vendeur; la ligne dudit emplacement est parallèle à et située à cent quatre-vingts pieds (480') de la ligne nord du lot No 735 du même cadastre, et la ligne est dudit emplacement est parallèle à et située à cent quarante pieds (140') de la ligne est du lot No 736 du même cadastre.Ainsi que le tout se trouve actuellement avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble et avec et sujet à une servitude de passage présentement créée en faveur des immeubles présentement vendus sur les immeubles suivants, savoir: o) Le lot numéro quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept cent quarante (740-4) au cadastre de la paroisse St-André-d'Argenteuil; b) Le lot numéro quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept cent trente-six (736-4) au cadastre de la paroisse St-André-d'Argenteuil; east, by a proposed and private street known as Tour-du-Lac Avenue and being a part of said lot No.733; in the rear, towards the west, by a proposed street being also a part of lot No.733; towards the north by another part of said lot No.733 belonging to Jean-Guy Levesque, pursuant to a deed registered under number 122605; and, on the other side, towards the south, by another part of said lot No.733 belonging to the vendor; the south line of the emplacement hereinabove described is parallel to and located at a distance of one hundred ten feet (110') from the north line of lot No.734 and the west line of the emplacement presently sold is parallel to and located at approximately at a distance of one hundred fifty feet (150') from the east line of lot No.736, all on said cadastre.2.A part of original lot number seven hundred thirty-six (Pt.736) on the cadastre of the Parish of St.André-d'Argentcuil, of square configuration, measuring two hundred feet (200') in width by a depth of two hundred feet (200'), English measure and more or less and bounded as follows, to wit: towards the north by a part of said lot No.733 being a proposed street; towards the east by a part of lot No.733 being a proposed street; towards the south and the west by other parts of said lot No.733 belonging to the vendor, the south line of said emplacement is parallel to and located at a distance of four hundred forty feet (440') from the north line of lot No.735 of same cadastre, and the east line of said emplacement is parallel to and located at a distance of one hundred forty feet (140') from the east line of lot No.736, of same cadastre.3.A part of original lot number seven hundred thirty-six (Pt.736) on the cadastre for the Parish of St.André-d'Argenteuil, of rectangular configuration, measuring one hundred feet (100') in width by a depth of two hundred feet (200'), English measure and more or less and bounded as follows, to wit: towards the south, by a part of lot No.733 being a proposed street; towards the east, by a part of said lot No.733 being a proposed street, towards the north and towards the west by other parts of said lot No.733 belonging to the vendor; the line of said emplacement is parallel to and located at a distance of four hundred eighty feet (480') from the north line of lot No.735 of same cadastre, and the east line of said emplacement is parallel to and located at a distance of one hundred forty feet (140) from the east line of lot No.736 of same cadastre.As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparcnt servitudes attaching to said immoveable and with and subject to a servitude of right of way presently created in favour of the immoveables presently sold on the following immoveables, to wit: (a) Lot number four of the official subdivision of original lot number seven hundred forty (740-4) on the cadastre for the Parish of St.André-d'Argenteuil; (6) Lot number four of the official subdivision of original lot number seven hundred thirty-six (736-4) on the cadastre for the Parish of St.André-d'Argenteuil; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n\" 10 2051 c) Les lots numéros cinq et six de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept cent trente-trois (733-5 et 6) au cadastre de la paroisse St-André-d\" Argenteuil; d) Une partie du lot originaire numéro sept cent trente-trois (ptie 733) au cadastre de la paroisse St-André-d'Argenteuil, appelée rue Tour du Lac, étant la continuation du lot No 733-5 et passant en front de l'immeuble ci-dessus décrit au paragraphe premier et allant jusqu'à la ligne nord dudit lot No 734; e) Différentes parties des lots numéros sept cent trente-trois et sept cent trente-six (pties 733 et 736) du même cadastre, bornant les emplacements présentement vendus pour se rendre des emplacements présentement vendus au Chemin Public et vice-versa; /) Une bande de terre du quarante pieds (40') de largeur, mesure anglaise, partant de la ligne est du Chemin Public et longeant la ligne nord des lots numéros sept cent trente-quatre, sept cent trente-cinq et sept cent quarante et un (734, 735 et 741) du même cadastre, ladite bande de terre étant prise à l'extrémité sud des lots numéros sept cent trente-trois, sept cent trente-six et sept cent quarante (733, 736 et 740) tous du même cadastre.Taxes municipales: $42.36.Coliseum Diversified Holdings Inc.\u2014 1° Un terrain de forme irrégulière étant connu et désigné aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Saint-André-d'Argenteuil, division d'enregistrement d'Argenteuil (De Carillon) et connu comme étant une partie du lot quatre (ptie 4).Borné au nord par une partie du lot numéro 4, mesurant trois cent seize pieds (316') dans sa ligne nord-ouest, par une partie du lot numéro 4 et mesurant mille quatre cent dix-neuf pieds et treize centièmes (1,419.13') et mille cinq cent soixante-dix pieds et quarante-quatre centièmes (1,570.44') dans sa ligne nord-est, par une partie du lot numéro 4 et mesurant cent pieds (100') dans sa ligne nord-ouest, par une partie du lot numéro 4 et mesurant mille sept cent vingt-cinq pieds (1,725.0') plus ou moins dans sa ligne nord-est, par une partie du lot numéro 4 et mesurant cent quatre-vingts pieds (180') plus ou moins dans sa ligne nord-ouest, par une partie du lot numéro 4 et mesurant neuf cent vingt-cinq pieds plus ou moins (925') dans sa ligne nord-est, par une partie du lot numéro 4 et mesurant trois cent quarante pieds plus ou moins (340') dans sa ligne nord-ouest, par une partie du lot numéro 4 et mesurant neuf cent dix pieds plus ou moins (910') et quatre cent vingt-cinq pieds plus ou moins (425') le long d'une courbe ayant un rayon de 1106', dans sa ligne nord-est, par une partie du lot numéro 4 et mesurant deux mille cinquante pieds plus ou moins (2,050') dans ses lignes nord-ouest, nord-est, ouest et est, par une partie du lot numéro 4, dans ses lignes sud-est, sud-ouest et nord-ouest par une partie de la ligne des hautes eaux de la rivière Outaouais, ayant une superficie de quinze millions de pieds carrés ds.ooo.ooo').(c) Lots numbers five and six of the official subdivision of original lot number seven hundred thirty-three (733-5 and 6) on the cadastre for the Parish of St.André-d'Argenteui I ; (d) A part of original lot number seven hundred thirty-three (Pt.733) on the cadastre.for the Parish of St.André-d'Argenteuil, called Tour-du-Lac Street, being the continuation of lot No.733-5 and passing in front of the immoveable hereinabove described in the first paragraph and proceeding up to the north line of said lot No.734; (e) Various parts of lots numbers seven hundred thirty-three and seven hundred thirty-six (Pt.733 and 736) of same cadastre, bounding the emplacements presently sold to reach the emplacements presently sold to the public road and conversely; (/) A strip of land of forty feet (40') in width, English measure, starting from the east line of the public road and running along the north line of lots number seven hundred thirty-four, seven hundred thirty-five and seven hundred forty-one (734, 735 and 741) of same cadastre, the said strip of land being taken at the south end of lots numbers seven hundred thirty-three, seven hundred thirty-six and seven hundred and forty (733, 736 and 740), all of same cadastre.Municipal taxes: $42.36.Coliseum Diversified Holdings Inc.\u2014 1.A piece of land of irregular figure, being known and designated upon the plan and book of reference of the official cadastre of the Parish of St.André-d'Argenteuil, Registry Division of Argenteuil (Carillon Island) and known as part of lot four (Pt.4).Bounded to the north by part of lot No.4, measuring three hundred and sixteen feet (316') in its northwest line by part of lot No.4 and measuring one thousand four hundred and nineteen feet and thirteen hundredths of a foot (1,419.13') and one thousand five hundred and seventy feet and forty-four hundredths of a foot (1,570.44') in its northeast line by part of lot No.4 and measuring one hundred feet (100') in its northwest line by part of lot No.4 and measuring one thousand seven hundred and twenty-five feet more or less (1.725.0') in its northeast line by part of lot No.4 and measuring one hundred and eighty feet (180') more or less, in its northwest line by part of lot No 4 and measuring nine hundred and twenty-five feet more or less (925.0') in its northeast line by part of lot No.\u2022* and measuring three hundred and forty feet more or less (340') in its northwest line by part of lot No.4 and measuring nine hundred and ten feet more or less (910') and four hundred and twenty-five feet more or less (425') along a curve having a radius of 1106', in its northeast line by part of lot No.4 and measuring two thousand and fifty feet more or less (2,050') in its northwest, northeast, west and east by part of lot No.4, in its southeast, southwest and northwest by part of the high water of the Outaouais River, and containing an area of fifteen million square feet (15,000,000.0'). 2052 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 Ce terrain est décrit sur un plan daté du 19 mai 1970, fait et préparé par Maurice Gaudreault, de Gaudreault, Rabin, Legault, Lacroix et Pigeon, arpenteurs-géomètres de Québec, sous la minute numéro 9143-11A et annexé à un acte de vente par Belavista Estates Inc., au vendeur ci-dessus, enregistré au bureau d'enregistrement d'Argenteuil sous le numéro 137166.Taxes municipales: $675.95.Gaétan McFadden, adresse inconnue.\u2014 Un emplacement situé à St-André d'Argenteuil, dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant une partie du lot originaire numéro sept cent trente (Ptie 730) au cadastre de la paroisse de St-André d'Argenteuil, comté d'Argenteuil, mesurant soixante-dix-huit (78) pieds de largeur en front dans sa ligne sud le long d'une rue privée connue et désignée comme étant le lot numéro six de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept cent trente (730-6) audit cadastre; soixante-quinze (75) pieds de largeur en arrière dans sa ligne nord le long d'une rue privée connue et désignée comme étant le lot numéro cinq de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept cent trente (730-5) audit cadastre; par des profondeurs d'environ cent soixante-dix (170) pieds dans sa ligne est et cent quarante (140) pieds dans sa ligne ouest, mesure anglaise et plus ou moins et borné comme suit: en front vers le sud par ladite rue privée portant le No 730-6; en arrière vers le nord par ladite rue privée portant le No 730-5 et des deux autres côtés par d'autres parties dudit lot originaire numéro 730; la ligne est dudit emplacement étant située à environ trois cents (300) pieds de la ligne de division des lots originaires numéros 730 et 726 dudit cadastre mesure anglaise et plus ou moins.Sans construction dessus érigée.Taxes municipales: $12.39; taxes scolaires: $9.61.Total: $22.00.Orra Investment Ltd.\u2014 1.Un emplacement situé à St-André dans le comté d'Argenteuil et composé comme suit: a) Des lots numéros dix, onze, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept cent quarante (740-10, 11, 18, 19, 20, 23) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-André.6) Des lots numéros neuf, treize, quatorze, de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept cent trente-six (736-9, 13, 14) auxdits plan et livre de renvoi officiels; c) Des lots numéros vingt et un, vingt-deux de la subdivision, officielle du lot originaire numéro sept cent quarante (740-21, 22) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-André.Taxes municipales: $94.79; taxes scolaires: $138.25.Total: $233.04.Fait à Lachute, Québec, ce 1er jour de mars 1974.Le secrétaire-trésorier, 56434-10-2-o Douglas R.Bradford.This piece of land is shown on a plan dated May 19th 1970 made and prepared by Maurice Gaudreault of Gaudreault, Rabin, Legault, Lacroix & Pigeon, Québec Land Surveyor, under minute number 9143-11A and annexed to a deed of sale by Belavista Estates Inc.to the vendor herein, registered at the Argenteuil Registry Office under the number 137166.Municipal taxes: $675.95.Gaétan McFadden, unknown address.\u2014 An emplacement located in St.André d'Argenteuil, in the County of Argenteuil, known and described as being a part of original lot number seven hundred thirty (Pt.730) on the cadastre for the Parish of St.André d'Argenteuil, County of Argenteuil, measuring seventy-eight (78) feet in width in front, on its south line along a private street known and described as being lot number six of the official subdivision of original lot number seven hundred thirty (730-6) on said cadastre; seventy-five (75) feet in width in rear on its north line along a private street known and described as being lot number five of the official subdivision of original lot number seven hundred thirty (730-5) on said cadastre; by approximate depths of one hundred seventy (170) feet on its east line and one hundred forty (140) feet on its west line, English measure and more or less, and bounded as follows: in front towards the south by the said private street bearing No.730-6; in rear towards the north by the said private street bearing No.730-5 and on the other two sides by other parts of said original lot number 730; the east line of said emplacement being located at approximately three hundred (300) feet from the dividing line of original lots numbers 730 and 726 of said cadastre, English measure and more or less.Without building erected, thereon.Municipal taxes: $12.39; school taxes: $9.61 Total: $22.00.Orra Investment Ltd.\u2014 1.An emplacement located in St.André in the County of Argenteuil and comprising the following: (a) Lots numbers ten, eleven, eighteen, nineteen, Hwenty, twenty-three of the official subdivision of original lot number seven hundred forty (740-10-11-18, 19, 20, 23) on the official plan and in the book of reference for the Parish of St.André.(6) Lots numbers nine, thirteen, fourteen of the official subdivision of original lot number seven hundred thirty-six (736-9, 13, 14) on said plan and book of reference; (c) Lots numbers twenty-one, twenty-two of the official subdivision of original lot number seven hundred forty (740-21, 22) on the official plan and in the book of reference for the Parish of St.André.Municipal taxes: $94.79; school taxes: $138.25.Total: $233.04.Dated at Lachute, Québec, this 1st day of March, 1974.Douglas R.Bradford, 56434-lO-2-o Secretary-Treasurer. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 2053 LA CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DES HOPITAUX DE SHERBROOKE (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 28 février 1973 par « LA CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DES HOPITAUX DE SHERBROOKE », changeant son groupe qui était « les employés des hôpitaux: Centre Hospitalier Universitaire (Université de Sherbrooke), Hôpital St-Vincent-de-Paul, Hôtel-Dieu de Sherbrooke » en celui de « les employés des hôpitaux: Centre Hospitalier Universitaire (Université de Sherbrooke), Hôpital St-Vincent-de-Paul de Sherbrooke, Hôtel-Dieu de Sherbrooke Inc., La Corporation de l'Hôpital d'Youville de Sherbrooke, le Centre de Services Sociaux de l'Estrie ».Québec, le 12 février 1974.Le sous-ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, 56338-o Albert Jessop.CAISSE D'ECONOMIE DES TRAVAILLEURS DE MARIEVILLE (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 18 septembre 1973 par la « CAISSE D'ECONOMIE DES TRAVAILLEURS DE MARIE-VILLE » changeant son groupe qui était « les employés des industries Civaco Wire Nails Manufacturing, Southern Demming « Crane » Industriel Fasteners » en celui de « les employés des industries ou institutions suivantes: Civaco Wire Nails Manufacturing Southern Demming « Crane » Industriel Fasteners, Centre d'Accueil de Rouville ».Québec, le 12 février 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 56339-o Albert Jessop.LA CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DES HOPITAUX DE SHERBROOKE (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, has approved the bylaw adopted on February 28, 1973, by \"LA CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DES HOPITAUX DE SHERBROOKE\", changing its group, which consisted of \"the employees of the following hospitals: Centre Hospitalier Universitaire (Université de Sherbrooke), Hôpital St-Vincent-de-Paul, Hôtel-Dieu de Sherbrooke to that of \"the employees of the following hospitals: Centre Hospitalier Universitaire (Université de Sherbrooke, Hôpital St-Vincent-de-Paul de Sherbrooke, Hôtel-Dieu de Sherbrooke Inc., La Corporation de l'Hôpital d'Youville de Sherbrooke and Centre de Services Sociaux de l'Estrie\".Québec, February 12, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 56338 Companies and Cooperatives.CAISSE D'ECONOMIE DES TRAVAILLEURS DE MARIEVILLE (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, has approved the bylaw adopted on September 18, 1973, by \"CAISSE D-ECONOMIE DES TRAVAn.LEURS DE MARIEVILLE\" changing its group, which consisted of \"the employees of the following industrial firms: Civaco Wire Nails Manufacturing and Southern Demming \"Cfane\" Industriel Fasteners\" to that of \"the employees of the following industrial firms or institutions: Civaco Wire Nails Manufacturing, Suth' era Demming \"Crane\" Industriel Fasteners and Centre d'Accueil de Rouville\".Québec, February 12, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 56339 Companies and Cooperatives.Demandes à la Législature Applications to Legislature EUGENE MARCOUX INC.MM.Eugène Marcoux et Michel Ladouceur et Dame Noëlla Morin-Marcoux donnent avis qu'ils déposent au Secrétariat des Commissions de l'Assemblée Nationale du Québec un projet de loi ayant pour objet de révoquer la dissolution de la compagnie « EUGENE MARCOUX LNC ».Sherbrooke, le 26 février 1974.Les procureurs des intéressés, 56362-10-4-o O'Breadt, Rivard & Bessette.EUGENE MARCOUX INC.Notice is given that Eugène Marcoux, Michel Ladouceur and Noëlla Morin-Marcoux are filing with the Secretariat of the Commissions of the National Assembly of the Province of Québec a bill in order to obtain the revocation of the dissolution of \"EUGENE MARCOUX INC\".Sherbrooke, February 26, 1974.O'Breadt, Rivard, & Bessette, 56362-10-4-o Attorneys for the Petitioners.Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions 2054 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9.1971,, Vol.10$, No.10 EATON REGULAR BAPTIST CHURCH Avis est par les présentes donné que Elwood Rolles-ton, employé du téléphone, r.r.2, Magog, Québec; James French, retraité, Sawyerville, Québec; et Robert Taylor, agriculteur, r.r.3, Sawyerville, Québec; adresseront une requête au Lieutenant Gouverneur en Conseil afin d'obtenir la constitution en corporation de « EATON REGULAR BAPTIST CHURCH », conformément aux dispositions de la Loi de la constitution de certaines Églises, chapitre 305, Statuts Refondus du Québec de 1964.Eaton, (Québec), 29 janvier 1974.Le procureur des requérants, 56022-7-4 Harry E.Grundy, c.r.EATON REGULAR BAPTIST CHURCH Notice is hereby given that Elwood Rolleston, telephone employee, R.R.2, Magog, Québec; James French, retired, Sawyerville, Québec; and Robert Taylor, farmer, R.R.3, Sawyerville, Québec; will apply by Petition to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec, for incorporation of the \"EATON REGULAR BAPTIST CHURCH\" under the provisions of the Church Incorporation Act, Chapter 305, Revised Statutes of Québec 1964.Eaton, Québec, January 29th 1974.Harry E.Grundy, q.c.56022-7-4-o Attorney for Petitioners.Communauté urbaine de Montréal Avis est par les présentes donné que la Communauté urbaiue de Montréal, ayant son siège social dans la Ville de Montréal, s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, à sa prochaine session, afin d'obtenir l'adoption d'une loi pour: 1.modifier la Loi de la Communauté urbaine de Montréal en vue de faciliter l'administration des affaires de cette dernière, de préciser certains dc ses pouvoirs et d'étendre certains délais prévus dans cette loi pour l'adoption de différentes mesures; 2° autoriser la Communauté à exproprier aux fins d'un meilleur aménagement des abords et à effectuer, sans expropriation préalable, des travaux en sous-sol lorsque ces travaux s'effectuent au-delà d'une profondeur déterminée; 3° dispenser la Communauté de faire approuver par le conseil les contrats accordés au plus bas soumissionnaire, lorsqu'il n'y a qu'un seul soumissionnaire; 4° prescrire les pénalités imposables en rapport avec les règlements concernant les aliments et prévoir des sanctions aux règlements dt la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal; 5° modifier les délais de dépôt et d'adoption du budget et préciser les dispositions relatives aux emprunts de la Communauté et de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal; 6° prévoir des dispositions relatives à la prescription des recours contre la Communauté et préciser quels sont les documents publics de la Communauté; 7° modifier la Loi du Boulevard métropolitain aux fins de prévoir que la Communauté n'exproprie plus et n'a plus à répartir pour les fins des voies latérales et prévoir l'arbitrage des différends concernant les repartitions du coût de ces voies latérales; et à diverses autres fins.Montréal, le 26ième jour dc février 1974.Les procureurs.Beaupré, Trudeau, Sylvestre 56343-10-4-o & Taillefer.Montreal Urban Community Notice is hereby given that Montreal Urban Community, having its corporate seat in the City of Montreal, will apply to the National Assembly of Québec at its next session to obtain the adoption of an Act so as to: 1.amend the Montreal Urban Community Act to facilitate the administration of said Community, clarify certain of its powers and extend certain delays prescribed in such Act for the adoption of various measures; 2.authorize the Community to expropriate for a bett-T lay-out of the approaches, and to effect underground works, without prior expropriation, provided such works are made beyond a prescribed depth; 3.dispense the Community of the approval of the Council for contracts awarded to the lowest bidder, whenever there is only one bidder; 4.prescribe penalties with respect to by-laws concerning food products and provide for sanctions to by-laws of the Montreal Urban Community Transit Commission ; 5.modify the delays for the filing and adoption of the budget and clarify provisions related to loans of the Community and the Montreal Urban Community Transit Commission; 6.include provisions concerning the prescription of claims against the Community and determine the public documents of the Community, 7.modify the Metropolitan Boulevard Act to provide that the Community docs no longer expropriate for purposes of the lateral roads and apportion the expenses therefor and provide for the arbitration of litigation concerning the apportionments of the cost of such lateral roads; and for various other purposes.Montreal, this 26th day of February 1974.Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 56343-10-4-o Attorneys. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n\" 10 2055 Ville d'Anjou Avis est donné que la Ville d'Anjou s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec, lors de sa prochaine session, pour obtenir l'adoption d'une loi spéciale en vue de refondre sa charte et obtenir certains pouvoirs nécessaires à la bonne administration de la Ville et, plus particulièrement, pour: 1° modifier les règlements d'emprunt de la Ville, pour répartir plus équitablement la charge des contribuables; 2° modifier, pour la Ville, la Loi sur l'évaluation foncière; 3° régulariser les titres de la Ville sur certains biens faisant partie du domaine public: parcs, rues et autres; 4° déclarer applicables à la Ville les dispositions de l'article 429, paragraphe 8 de la Loi des cités et villes, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions; 5° établir un fonds résidentiel; 6\" emprunter au fonds de roulement pour défrayer certaines dépenses préliminaires, de nature capitale; et tous autres amendements qu'elle jugera nécessaires ou utiles pour la bonne administration des affaires de la Ville et de ses citoyens.Donné à Ville d'Anjou, le 21 février 1974.Les procureurs de la Ville d'Anjou, Me Armand Poupart, 56336-10-4-o Me François Wilhelmy, avocats.La Communauté urbaine de Québec Avis est par les présentes donné que la Communauté urbaine de Québec s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec, au cours de la présente session, pour demander l'adoption d'une loi amendant sa loi constitutive pour en modifier les annexes, et entre autres dispositions, les définitions, la façon générale d'exercer ses pouvoirs, la procédure de mise en candidature à la charge de membre du comité exécutif, la durée des mandats et la procédure permettant de combler les vacances, la participation de la Communauté au paiement d'une partie de la pension du président du comité exécutif, les pouvoirs du comité exécutif, la composition du Conseil, la procédure de fixation de la date des assemblées du Conseil et la procédure dc convocation, le calcul de la rémunération des membres du Conseil, la procédure de votation aux commissions du Conseil, les devoirs du secrétaire, les pouvoirs et la compétence de la Communauté, la procédure d'appel d'offres, les dispositions ayant trait à l'évaluation foncière, les titres de la Communauté sur ses terrains industriels, la procédure de disposition d'immeubles, certaines dispositions financières relatives aux emprunts et aux garanties, certaines dispositions concernant les modalités de perception de la répartition, certaines dispositions concernant le territoire périphérique, certaines Town of Anjou Notice is hereby given that the Town of Anjou will apply to the National Assembly of the Province of Québec, at its next session, for a special Act revising its charter and granting certain powers in view of the proper administration of its affairs and, more specifically: 1.To amend the loan by-laws of the City, in order to distribute more equitably the share of the taxpayers; 2.To amend, with respect to the municipality, the Real Estate Assessment Act; 3.To fix proper titles on certain immoveables forming part of the public property, such as parks, streets and others; 4.To declare that the provisions of Section 429, paragraph 8, of the Cities and Towns Act shall apply to the Town of Anjou, as of the coming into force of such provisions; 5.To establish a residential fund; 6.To borrow from the sinking fund, in order to pay preliminary expenses for capital works; and such other amendments, which it may deem useful and necessary for the proper administration of its affairs and those of the citizens.Town of Anjou, February 21, 1974.Me Armand Poupart, Me François Wilhelmy, Advocates, 56336-10-4-o The Attorneys for the Town of Anjou.Québec Urban Community Notice is hereby given that the Québec Urban Community will petition the National Assembly of the Province of Québec, at is present session, to modify it's schedules and the dispositions of its constitutive law, among others, to wit: the definitions, the general exercise of its powers, the procedure of nomination as a candidate for the Executive Committee, the term of office, the filling up procedure of vacancies, the Community's participation to the payment of a part of the Executive Committee Chairman's pension plan, the Executive Committee's powers, the composition of the Council, the procedure to determine the Council's meeting's date and convocations' procedure, the computation of the Council's members' remuneration, the voting procedure at the committees of the Council, the secretary's duties, the powers and competence of the Community, the calling for tenders' procedure, the real estate assessment's provisions, the titles of the Community on its industrial land, the procedure to dispose of its immoveables, some financial provisions relating to loans and guaranties, some provisions concerning collection of the apportionment of expenses, some provisions concerning the peripheral territory, some provisions concerning the preparation and the execution of the development plan, the GQVVPB and 2056 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.18 dispositions concernant l'élaboration et la mise en oeuvre du schéma d'aménagement, le financement du BAEQM et de la CTCUQ, la répartition du déficit de la CTCUQ, ainsi que certaines dispositions financières et autres concernant la régie interne de la CTCUQ, et pour toute autre disposition.Québec, ce 00 février 1974.Les avocats, 56269-9-4-0 Yvan Dallaire et Jacques Forgues.Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.JULIETTE Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( AETERNA-VIE COMPA-No 05-009094-73X GNIE D'ASSURANCE, cor- t poration légalement constituée ayant son siège social à Montréal, district de Montréal, partie demanderesse, vs PATSY DI FABIO, domicilié et résidant à 7217 rue l'Assomption, St-Léonard, district de Montréal, partie défenderesse.« Un certain emplacement composé des lots numéros cent quarante-huit et cent quarante-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro soixante-dix-sept (77-148 et 149) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Charles-Borromée, division d'enregistrement de Joliette, avec la maison dessus érigée et portant le numéro 339 de la rue Marsolais, à Joliette, province de Québec.» Pour être vendu au bureau de la division d'enregistrement de Joliette, 577 rue Notre-Dame, Joliette, des comté et district de Joliette.JEUDI, le VLNGT-CLNQUIÈME jour d'AVRIL 1974, à ONZE heures de I'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Christian Roy.Joliette, le 25 février 1974.56418-0 MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Canada ¦\u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal I INDIVIDUAL INVESTMENT No 05-012 075-73.< A CORP., BORTHERS TRAD-' ING CORP., et ACE MORT-GAGE CORP., tous corps politiques et constitués, QUCTC financing, the QUCTC deficit apportionment, and some financial provisions and other provisions pertaining to the QUCTC administration; and any other provisions.Québec, this February 00, 1974.Yvan Dallaire and Jacques Forgues, 56269-9-4-o Lawyers.Sheriffs Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have leen seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.JOLIETTE Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District de Montreal I AETERNA-VIE, COMPA-No.05-009094-73X GNIE D'ASSURANCE, a I corporation legally incorporated, with its head office in Montreal, District of Montreal, plaintiff, versus PATSY DI FABIO, domiciled and residing at 7217 l'Assomption Street St.Léonard, District of Montreal, defendant.\"A certain emplacement consisting of lots numbers one hundred forty-eight and one hundred forty-nine of the official subdivision of original lot number seventy-seven (77-148 and 149) on the official plan and in the book of reference of the cadastre for the Parish of St.Charles-Borromée, Registration Division of Joliette, with the house erected thereon bearing number 339 Marsolais Street, in Joliette, Province of Québec.\" To be sold at the office of the Registration Division of Joliette, 577 Notre-Dame Street Joliette, in the County and District of Joliette, on THURSDAY, the TWENTY-FIFTH day of APRIL 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Christian Roy, Sheriff's Office, Sheriff.Joliette, February 25, 1974.56418 MONTREAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( INDIVIDUAL INVESTMENT No.05-012 075-73.< A CORP., BORTHERS TRAD-l ING CORP., and ACE MORTGAGE CORP., all bodies politic and corporate, duly GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n\" 10 2057 dûment constitués en corporation suivant la loi, chacun ayant son siège social et principal bureau d'affaires en les ville et district de Montréal, au 4770, avenue Kent, demanderesses, vs GILLES MARIER, administrateur, résidant et domicilié au 1929, boulevard de Maisonneuve, en les ville et district de Montréal, défendeur.« Une propriété immobilière située en la ville de Montréal, connue et désignée comme étant la resubdivision numéro cinq de la subdivision numéro soixante-douze du lot originaire numéro mille six cent cinquante-quatre (1654-72-5) aux plan et livre de renvoi officiels du quartier Saint-Antoine en la ville de Montréal, ledit emplacement mesurant vingt-sept pieds (27') de longueur sur une largeur de cent vingt-cinq pieds et quatre dixièmes et couvrant une superficie totale de trois mille trois cent quatre-vingt-trois pieds carrés (3,383 pi.c.), mesure anglaise, plus ou moins, avec l'immeuble dessus construit portant le numéro civique 1929, boulevard de Maisonneuve, le tout dans son état actuel, avec toutes les servitudes et droits s'y rattachant sans exception ni réserve, sauf et à distraire de ladite propriété, une partie dudit lot qui doit être expropriée par la ville de Montréal, conformément à un acte de prise de possession et au certificat du protonotaire, enregistrés à Montréal sous les numéros 2197766 et 2237937.» Pour être vendu au bureau du Shérif, Palais de Justice de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le ONZIÈME jour d'AVRIL 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 21 février 1974.56419 Fieri Facias de Terris Canada \u2014¦ Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal [TE DIMANCHE MATIN No 05-OO3310-73.< *-> (1967) LTEE, demanderesse t vs LES MAISONS TRADITION DU QUEBEC LTEE, défenderesse.a) « Un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro dix-sept du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-17) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-Mag-deleine, avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 10 boulevard Des Champs Fleuris, Laprairie; » b) « Un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro vingt-cinq du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-25) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de La-prairie-de-la-Magdeleine, avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 145 rue Des Colibris, Laprairie; » c) « Un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro trente du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-30) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine, avec bâtisse y dessus en voie de cons- incorporated according to law, having their head offices and principal places of business in the City and District of Montrealat 4770 Kent Avenue, plaintiffs, vs GILLES MARIER, administrator, residing and domiciled at 1929 de Maisonneuve Blvd., in the City and District of Montreal, defendant.\"An immoveable property situated in the City of Montreal, and known and described as being re-subdivision number five of subdivision number seventy-two of original lot number one thousand six hundred fifty-four (1654-72-5) on the official plan and book of reference of the Quartier Saint-Antoine in the City of Montreal, the said emplacement measuring twenty-seven feet (27') in length one hundred twenty-five feet and four tenths of foot in width and containing a total area of three thousand three hundred eighty-three square feet (3,383 s.f.) English measure and more or less, with the immoveable property thereon erected bearing civic No.1929 de Maisonneuve Blvd.the whole as same presently exists, with all servitudes and rights thereto attached without exception or reserve, but to be deducted therefrom part of said lot expropriated by the City of Montreal in accordance with an Act of prise de possession and certificate of the Prothonotary registered at Montreal under Nos.2197766 and 2237937.\" To be sold at the Sheriff's Office, Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th floor.Room 56, on the ELEVENTH day of APRIL 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff, Montreal, February 21, 1974 .56419-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal (TE DIMANCHE MATIN No.05-003310-73X (1967) LTEE.plaintiff vs l LES MAISONS TRADITION DU QUEBEC LTEE, defendant.(a) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number seventeen of original lot number three hundred twenty-one (321-17) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-Ia-Magdeleine, with the building under construction thereon bearing civic number 10 Des Champs Fleuris Boulevard, Laprairie;\" (6) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number twenty-five of original lot number three hundred twenty-one (321-25) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, with the building under construction thereon bearing civic number 145 Des Colibris Street, Laprairie;\" (c) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number thirty of original lot number three hundred twenty-one (321-30) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-Ia-Magdeleine, with the building under 2058 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1971,, Vol.106, No.10 traction portant le numéro civique 70 boulevard Des Champs Fleuris, Laprairie; » d) « Un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro quarante du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-40) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de La-prairie-de-la-Magdeleinc avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 100 rue De La Lune, Laprairie; » e) « Un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro cinquante-huit du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-58) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 20 rue De La Lune, Laprairie; » - /) « Un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro soixante-cinq du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-65) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine, avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 25 boulevard Des Champs Fleuris, Laprairie; » g) « Un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro soixante-six du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-66) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 35 boulevard Des Champs Fleuris, Laprairie; » h) « Un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro soixante-sept du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-67) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine, avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 45 boulevard Des Champs Fleuris, Laprairie; » t) « Un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro soixante-dix du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-70) aux plan et livre de renvoi officiels dc [a paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine, avec bâtisse y dessus en voie dc construction portant le numéro civique 75 boulevard Des Champs Fleuris, Laprairie; » j) * Un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro soixante et onze du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-71) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine, avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 85 boulevard Des Champs Fleuris, Laprairie; » k) « Un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro soixante-douze du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-72) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine, avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 95 boulevard Des Champs Fleuris, Laprairie; » I) « Certains lots dc terre vague situés en la ville de Laprairie, connus et désignés comme étant les lots numéros douze à seize inclusivement; dix-huit à vingt- construction thereon bearing civic number 70 Des Champs Fleuris Boulevard, Laprairie;\" (d) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number forty of original lot number three hundred twenty-one (321-40) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine with the building under construction thereon bearing civic number 100 De La Lune Street, Laprairie;\" (e) \"A certain emplacement known and described as being subdivision fifty-eight of original lot number three hundred twenty-one (321-58) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine with the building under construction thereon bearing civic number 20 De La Lune Street, Laprairie;\" (/) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number sixty-five of original lot number three hundred twenty-one (321-65) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, with the building under construction thereon bearing civic number 25 Des Champs Fleuris Boulevard, Laprairie;\" (g) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number sixty-six of original lot number three hundred twenty-one (321-66) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, with the building under construction thereon bearing civic number 35 Des Champs Fleuris Boulevard, Laprairie;\" (A) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number sixty-seven of original lot number three hundred twenty-one (321-67) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, with the building under construction thereon bearing civic number 45 Des Champs Fleuris Boulevard, Laprairie;\" (t) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number seventy of original lot number three hundred twenty-one (321-70) of the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, with the building under construction thereon bearing civic number 75 Des Champs Fleuris Boulevard, Laprairie;\" (j) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number seventy-one of original lot number three hundred twenty-one (321-71) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, with the building under construction thereon bearing civic number 85 Des Champs Fleuris Boulevard, Laprairie;\" (k) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number seventy-two of original lot number three hundred twenty-one (321-72) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, with the building under construction thereon bearing civic number 95 Des Champs Fleuris Boulevard, Laprairie;\" (/) \"Certain vacant lots located in the Town of Laprairie, known and described as being lots numbers twelve to sixteen inclusive; eighteen to twenty-three GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 2059 trois inclusivement; vingt-six à vingt-neuf inclusivement; trente et un; trente-trois à trente-cinq inclusivement; trente-huit; trente-neuf; quarante et un à cinquante-deux inclusivement; cinquante-quatre à cinquante-sept inclusivement; cinquante-neuf à soixante-quatre inclusivement; soixante-huit; soixante-neuf; soixante-quatorze à soixante-dix-sept inclusivement; soixante-dix-neuf à cent quatre inclusivement; cent six à cent dix-huit inclusivement; cent trente-deux à deux cent trente inclusivement; deux cent quarante-huit à trois cent vingt-trois inclusivement de la subdivision officielle du lot originaire trois cent vingt et un (321-12) à 321-16 inclusivement; 321-18 à 321-23 inclusivement; 321-26 à 321-29 inclusivement; 321-31; 321-33 à 321-35 inclusivement; 321-38; 321-39; 321-41 à 321-52 inclusivement; 321-54 à 321-57 inclusivement; 321-59 à 321-64 inclusivement; 321-68; 321-69; 321-74 à 321-77 inclusivement; 321-79 à 321-104 inclusivement; 321-106 à 321-118 inclusivement; 321-132 à 321-230 inclusivement; 321-248 à 321-323 inclusivement) au cadastre officiel de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.division d'enregistrement de Laprairie.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Laprairie, à 214 St-Ignace, à Laprairie, P.Q., le DIXIÈME jour d'AVRIL 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 4 mars 1974.56422-o QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( T-TELLER-NATOFIN LTD., cor-Cour Supérieure,} poration légalement consti-No 15-852.\\ tuée, ayant une place d'affaires à ' Montréal, et un bureau à Québec, 4 Parc Samuel Holland, Cité et district de Québec, contre JACQUES FRANCO, c.a.en sa qualité de Syndic aux biens de MONTMARTRE CONSTRUCTION INC., en faillite et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Québec, mis en cause.« Une partie non subdivisée du lot cinq cent soixante-quinze (575) du cadastre officiel pour la paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, division d'enregistrement de Québec, contenant en superficie deux cent cinq mille cent vingt-cinq pieds carrés (205,125 p.c.) plus ou moins, mesure anglaise, bornée au nord-est par le lot 575-2 n.s., du cadastre susdit, au nord-ouest par la rue Costebelle, au sud-ouest par le boulevard L'Ormière et au sud-est par les lots 53-4, 53-5 et 53 n.s.du cadastre officiel de la paroisse de l'Ancienne-Lorette.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, le ONZIÈME jour d'AVRIL, 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 4 mars 1974.56420-c inclusive; twenty-six to twenty-nine inclusive; thirty-one; thirty-three to thirty-five inclusive; thirty-eight; thirty-nine; forty-one to fifty-two inclusive; fifty-four to fifty-seven inclusive; fifty-nine to sixty-four inclusive; sixty-eight; sixty-nine; seventy-four to seventy-seven inclusive; seventy nine to one hundred four inclusive; one hundred six to one hundred eighteen inclusive; one hundred thirty-two to two hundred thirty inclusive; two hundred forty-eight to three hundred twenty-three inclusive of the official subdivision of original lot three hundred twenty-one (321-12 to 321-16 inclusive; 321-18 to 321-23 inclusive; 321-26 to 321-29 inclusive; 321-31; 321-33 to 321-35 inclusive; 321-38; 321-39; 321-41 to 321-52 inclusive; 321-54 to 321-57 inclusive; 321-59 to 321-64 inclusive; 321-68 ; 321-69; 321-74 to 321-77 inclusive; 321-79 to 321-104 inclusive; 321-106 to 321-118 inclusive; 321-132 to 321-230 inclusive; 321-248 to 321-323 inclusive) on the official cadastre for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, Laprairie Registration Division.\" To be sold at the Laprairie Registry Office, 214 St.Ignace, in Laprairie, P.Q., on the TENTH day of APRIL 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, March 4, 1974.56422-0 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit:/\" T-JELLER-NATOFLN LTD., a cor-Supcrior Court, J * ¦*\u2022 poration legally incorporated, No.15-852.J having a place of business in Mont-f, real and an office in Québec City, at 4 Samuel Holland Park, City and District of Québec, versus JACQUES FRANCO, c.a., in his capacity as trustee of the property of MONTMARTRE CONSTRUCTION INC., in bankruptcy, and THE REGISTRAR of the Québec Registration Division, mis en cause.\"A non subdivided part of lot five hundred seventy-five (575) of the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Québec Registration Division, covering an area of two hundred five thousand one hundred twenty-five square feet (205,125 sq.ft.), more or less, English measure, bounded on the northeast by lot 575-2 n.s., on said cadastre, on the northwest by Costebelle Street, on the southwest by L'Ormière Boulevard and on the southeast by lots 53-4, 53-5 and 53 n.s.on the official cadastre for the Parish of l'Ancienne-Lorette.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec, on the ELEVENTH day of APRIL, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, March 4, 1974.56420 2060 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March '9, 1974, Vol.106, No.10 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( T3AGÉ LIMITÉE, société légale, Cour Provinciale, ) -*\u2022 ayant son siège social à Char-No 108-930.l lesbourg Ouest, district de Québec, { versus ERNEST BRADETTE, domicilié à 9, rue des Trembles, Lac St-Charles, district de Québec.« Un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant la subdivision neuf du lot originaire numéro neuf cent quatre-vingt (980-9) du cadastre officiel pour la paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, division d'enregistrement de Québec, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances et notamment l'immeuble situé à 9, rue des Trembles, Lac St-Charles.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, le ONZIÈME jour du mois d'AVRIL 1974 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 4 mars 1974.56421-0 SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de St-François t T AFLEUR ÉLECTRIQUE INC., cor-No 37-333.\\ poration légalement constituée l ayant sa principale place d'affaires à 1189 Bowen sud, en la cité de Sherbrooke, district de St-François, demanderesse, M HENRI GAGNÉ, domicilié à R.R.No 1, St-Élie, district de St-F rançois, défendeur, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Sherbrooke, mis en cause.« Un certain terrain de forme irrégulière connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton d'Orford comme étant une partie du lot numéro sept cent trente-neuf (739 Ptie) mesurant soixante-quinze pieds (75') dans les lignes nord-ouest et sud-est, cent pieds dans les lignes nord-est et sud-ouest et plus au long décrit comme suit, à savoir: Partant d'un point « A » sur plan situé dans la ligne ouest du nouveau chemin public de quatre-vingt pieds (80') de largeur et dans la ligne nord-ouest du lot 733, de là, dans une direction sud-est, en suivant la ligne sud-ouest dudit chemin, une distance de trois cent cinquante-cinq pieds (355') jusqu'à un point « B » sur plan étant aussi le coin est du terrain à décrire; de là, tournant un angle de quatre-vingt-quatre degrés, quarante-trois minutes et vingt-cinq secondes (84°-43'-25\") avec le prolongement de la droite E-B (plus bas décrite) dans une direction sud-ouest, en ligne droite une distance dc soixante-quinze pieds (75') jusqu'à un point « C » sur plan; de là, tournant vers la droite un angle de quatre-vingt-quinze degrés, seize minutes, trente-cinq secondes (95 -16'-35\") .dans une direction nord-ouest en ligne droite, une Fieri Facias de Terris Québec, to wit : ( pAGÉ LIMITÉE, a corporation Provincial Court,) legally constituted, having its No.108-830.) head office in Charlesbourg-West, { District of Québec, versus ERNEST BRADETTE, domiciled at 9 Des Trembles Street, Lac St.Charles, District of Québec.\"A piece of land or emplacement known and described as subdivision nine of original lot number nine hundred and eighty (980-9) of the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Québec Registration Division, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies and particularly the building situated at 9 Des Trembles Street, Lac St.Charles.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec City, on the ELEVENTH day of APRIL, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, March 4, 1974.56421 SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Saint-François I T AFLEUR ÉLECTRONIQUE INC., No.37-333.S ™ a corporation legally incorporated I having its principal place of business at 1189 Bowen South, in the City of Sherbrooke, District of Saint-François, plaintiff, vs HENRI GAGNÉ, domiciled at St.Élie, R.R.No.1, District of Saint-François, defendant, and THE REGISTRAR for the Sherbrooke Registration Division, mis en cause.\"A certain piece of land of irregular configuration known and described on the official plan and in the book of reference for the Township of Orford as forming part of lot number seven hundred thirty-nine (739 Pt.) measuring seventy-five feet (75') on the northwest and southeast lines, one hundred feet on the northeast and southwest lines and more fully described as follows, to wit: Starting at a point \"A\" on a plan, located on the west line of the new public road which measures eighty feet (800 in width and on the northwest line of lot 733, thence, in a southeasterly direction, along the southwest line of said road, a distance of three hundred fifty-five feet (355') up to a point \"B\" on a plan, being also the easterly corner of the piece of land to be described; thence, turning at an angle of eighty-four degrees, forty-three minutes and twenty-five seconds (84°-43'-25\") with the extension of the straight line E-B (hereinafter described) in a southwesterly direction, a distance of seventy-five feet (75') in a straight line up to the point \"C\" on the plan; thence, turning to the right at an angle of ninety-five degrees, sixteen minutes, thirty-five seconds (95°-16'-35\") .in a northwesterly direction in a straight line, a distance of one hundred GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1971,, 106' année, n° 10 2061 distance de cent pieds jusqu'à un point « D » sur plan, de là, tournant vers la droite un angle de quatre-vingt-quatre degrés, quarante-trois minutes, vingt-cinq secondes (84°-43'-25\") dans une direction nord-est, en ligne droite, une distance de soixante-quinze pieds (75') jusqu'à un point « E » sur plan situé dans la ligne sud-ouest de l'ancien chemin public; de là, dans une direction sud-est en suivant la ligne sud-ouest de l'ancien chemin public pour une partie et du nouveau chemin public pour la seconde partie une distance de cent pieds (100'), distance mesurée en ligne droite entre les points « E » et « B », jusqu'à un point « B » sur plan point de départ.Le terrain ainsi décrit est borné au nord-est par une partie de l'ancien chemin public et une partie du nouveau chemin public, au sud-est, au sud-ouest et au nord-ouest par partie du lot No 739 (propriété du vendeur).Le terrain plus haut décrit contient une superficie de sept mille six cent trente pieds carrés (7630 pi.car.).Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, situé sur le Grand Chemin menant à Valcourt.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Sherbrooke, MARDI, le SEIZIÈME jour d'AVRIL 1974, à DIX heures de la matinée.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Palais de Justice, Jean-Guy Bisson.Sherbrooke, Que., ce 26 février 1974.56288-0 SAINT-HYACINTHE Canada \u2014 Province de Québec District de Saint-Hyacinthe Cour Supérieure, l CONSTRUCTION ST-PAUL No 20320.\\ ' LTÉE, demanderesse, vs SA-' NAIR INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR, du bureau d'enregistrement, division de Bagot, mis en cause.Cette propriété étant une partie du lot cent quatre-vingt-sept (P.187;, le lot cent quatre-vingt-onze (P.191;, une partie des lots cent quatre-vingt-quatorze (P.194), cent quatre-vingt-quinze (P.195; et cent quatre-vingt-seize (P.196; au cadastre de la paroisse de Saint-Pie, division d'enregistrement de Bagot, peut être plus particulièrement décrite comme suit: 1.Description: 1.1 Parcelle « 1, 2, 3, 4 », partie du lot 187: Commençant au point « 1 » du plan ci-joint, lequel point est situé à l'intersection des lots 187, 191 et 188.Du point « 1 », une distance de quatre cent quinze pieds (415.0) a été mesurée dans une direction nord quarante-deux degrés, cinq minutes ouest (N.42°05'W.;, jusqu'au point « 2 ».Du point « 2 », une distance de cinq cent vingt-cinq pieds et quatre dixièmes (525.4) a été mesurée dans une feet up to point \"D\" on the plan; thence, turning to the right at an angle of eighty-four degrees, forty-three minutes, twenty-five seconds (84°-43'-25\") in a northeasterly direction, in a straight line, a distance of seventy-five feet (75') up to a point \"E\" on the plan, located on the southwest line of the former public road; thence, in a southeasterly direction along the southwest line of the former public road for one part, and of the new public road for the second part, a distance of one hundred feet (100'), measured in a straight line between points \"E\" and \"B\", up to point \"B\" on the plan, to the starting point.The piece of land above described is bounded on the northeast by a part of the former public road and a part of the new public road, on the southeast, the southwest and the northwest by part of lot number 739 (property of the vendor).The piece of land hereinabove described covers a surface area of seven thousand six hundred thirty square feet (7630 sq.ft.).With the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, located on the Grand Chemin that leads to Valcourt.\" To be sold at the Sherbrooke Registry Office, on TUESDAY, the SIXTEENTH day of APRIL, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Jean-Guy Bisson, Court House, Assistant Sheriff.Sherbrooke, Que., February 26, 1974.56288 SAINT-HYACINTHE Canada \u2014 Province of Québec District of St.Hyacinthe Superior Court, I CONSTRUCTION ST.PAUL No.20320.< ^ LTEE, plaintiff, vs SANAIR t INC., defendant, and THE REGISTRAR Registration Division of Bagot, mis en cause.That property being part of lot number one hundred and eighty-seven (Pt.No.187), lot number one hundred and ninety-one (Pt.No.191), part of lots numbers one hundred and ninety-four (Pt.No.194), one hundred and ninety-five (Pt.No.195), and one hundred and ninety-six (Pt.No.196) on the cadastre of the Parish of St.Pie Registration Division of Bagot, which may be more particularly described as follows: 1.Description: 1.1 Plot of land \" 1,2,3,4\" part of lot 187 : Starting at a point « 1 » of the appended plan, which point is situated at the intersection of lots 187, 191, and 188.From point \"1\", a distance of four hundred and fifteen feet (415.0') measured in a direction North forty-two degrees, five minutes West (N.42°05 W.), to a point \"2\".From point \"2\", a distance of five hundred and twenty-five and four tenths (525.4') measured in a di- 2062 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 direction nord quarante-six degrés, trente-trois minutes est (N.46°33' E), jusqu'au point « 3 ».Du point « 3 ».une distance de quatre cent six pieds et huit dixièmes (406.8) a été mesurée dans une direction sud quarante-huit degrés, huit minutes est (S.48°08' E), jusqu'au point « 4».Du point « 4 », une distance de cinq cent soixante-quatorze pieds et cinq dixièmes (574.5) a été mesurée dans une direction sud quarante-cinq degrés, trente-quatre minutes ouest (S.45°34' W.) jusqu'au point « 1 », point de départ.Ce terrain est borné au nord-est par le résidu du lot 187, au sud-est par une partie du lot 191.au sud-ouest par le lot 188 et une partie du lot 187, au nord-ouest par une partie du lot 184 et contient, en superficie, deux cent vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit pieds carrés (225,488).1.2 Parcelle « 1, 4, 5, 6, 7, 8 », lot 191 : Commençant au point « 1 » du plan ci-joint, lequel point est situé à l'intersection des lots 187, 191 et 188.Du point « 1 », une distance de cinq cent soixante-quatorze pieds et cinq dixièmes (574.5) a été mesurée dans une direction nord quarante-cinq degrés, trente-quatre minutes est (N.45°34' E.), jusqu'au point « 4 ».Du point « 4 », une distance de cent trente-huit pieds et deux dixièmes (138.2) a été mesurée dans une direction sud quarante-deux degrés, vingt-neuf minutes est (S.42\"29' E.), jusqu'au point « 5 ».Du point « 5 », une distance de deux cent soixante-cinq pieds et trois dixièmes (265.3) a été mesurée dans une direction sud quarante-six degrés, dix minutes est (S.46°10' E.), jusqu'au point « 6 ».Du point « 6 », une distance de deux mille huit cent soixante-cinq pieds et deux dixièmes ((2865.2) a été mesurée dans une direction sud quarante-six degrés, vingt-huit minutes ouest (S.46°28' W.), jusqu'au point* 7 ».Du point < 7 », une distance de trois cent quatre-vingt-un pieds (381.0) a été mesurée dans une direction nord quarante-trois degrés, douze minutes ouest (N.43°12' W.), jusqu'au point « 8 ».Du point « 8 », une distance de deux mille deux cent soixante-dix-neuf pieds (2279.0) a été mesurée dans une direction nord quarante-six degrés, neuf minutes est (N.46°09' E.), jusqu'au point « 1 », point de départ.Ce terrain est borné au nord-est par le lot 192, au sud-est par le lot 194, au sud-ouest par le chemin du Petit Rang St-François, au nord-ouest par les lots 190, 188 et une partie du lot 187 et contient, en superficie, un million, cent treize mille, deux cent quatre-vingt-onze pieds carrés (1,113,291).1.3 Parcelle « 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 », partie du lot 194: Commençant au point « 6 » du plan ci-joint, lequel point est situé à l'intersection des lots 192, 193, 194 et 191.Du point « 6 », une distance de cent soixante-dix pieds et quatre dixièmes (170.4) a été mesurée dans une direction sud quarante-trois degrés, vingt et une minutes est (S.43°21' E.), jusqu'au point « 9 ».rection North forty-six degrees, thirty-three minutes East (N.46°33'E.), to a point \"3\".From point \"3\", a distance of four hundred and six and eight tenths (406-8') measured in a direction South forty-eight degrees, eight minutes East (S.48°08' E.), up to a point \"4\".From point \"4\", a distance of five hundred and seventy-four and five tenths (574.5') measured in a direction South forty-five degrees, thirty-four minutes West (S.45°34' W.), up to a point \"1\", the starting point.This piece of land is bounded on the northeast by the remainder of lot 187, on the southeast by part of lot 191, on the southwest by lot 188, and part of lot 187, on the northwest by part of lot 184 and contains two hundred and twenty-five thousand four hundred and eightv-eight square feet (225,488 sq.ft.).1.2 Plot of land \"1,4,5,6,7,8\", lot 191 : Starting at a point \"1\" on the appended plan, which point is situated at the intersection of lots 187, 191 and 188.From point \"1\", a distance of five hundred and seventy-four and five tenths (574.5') measured in a direction North forty-five degrees, thirty-four minutes East (N.45°34' E.), to a point \"4\".From point \"4\", a distance of one hundred and thirty-eight and two tenths (138.2') measured in a direction South forty-two degrees, twenty-nine minutes East (S.42°29' E~), to a point \"5\".From point \"5\", a distance of two hundred and sixty-five and three tenths (265.3') measured in a direction South forty-six degrees, ten minutes East (S.46°10' E), to a point \"6\".From point \"6\", a distance of two thousand eight hundred and sixty-five and two tenths (2865.2') measured in a direction South forty-six degrees, twenty-eight minutes West (S.46°28' W.), to a point \"7\".From point \"7\", a distance of three hundred and eighty-one feet (381') measured in a direction North forty-three degrees, twelve minutes West (N.43°12'W.), to a point \"8\".From point \"8\", a distance of two thousand two hundred and seventy-nine feet (2279.0') measured in a direction North forty-six degrees, nine minutes East (N.46°09' E.), to point \"1\", the point of departure.This piece of land is bounded on the northeast by lot 192, on the southeast by lot 194, on the southwest by Petit Rang St-François Road, on the northwest by lots 190, 188 and part of lot 187 and contains one million one hundred and thirteen thousand two hundred and ninety-one square feet (1,113,291 sq.ft.).1.3 Parcels \"6, 9,10, 11, 12, 13,14,15, 7\", part of lot 194: Starting at a point \"6\" on the plan attached hereto, which point is located at the intersection of lots 192, 193,194 and 191.From point \"6\", a distance of one hundred seventy and four tenths feet (170.4') measured in a direction South forty-three degrees, twenty-one minutes East (S.43°21' E.), up to a point \"9\". GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1971,, 106' année, n' 10 2063 Du point « 9 », une distance de deux mille trois cent quatre-vingt-douze pieds et sept dixièmes (2392.7) a été mesurée dans une direction sud quarante-six degrés, cinquante minutes ouest (S.46°50' W.), jusqu'au point «10».Du point « 10 », une distance de deux cent quinze pieds et deux dixièmes (215.2) a été mesurée dans une direction sud soixante-douze degrés, trente-sept minutes ouest (S.72°37' W.), jusqu'au point « 11 ».Du point « 11 », une distance de vingt-quatre pieds et quatre dixièmes (24.4) a été mesurée dans une direction sud quarante-quatre degrés, huit minutes ouest (S.44°08' W.), jusqu'au point « 12 ».Du point « 12 », une distance de quatre-vingt-quatorze pieds et quatre dixièmes (94.4) a été mesurée dans une direction sud vingt et un degrés, vingt-trois minutes est (S.21°23' E.), jusqu'au point « 13 ».Du point « 13 », une distance de deux cent quinze pieds et deux dixièmes (215.2) a été mesurée dans une direction sud quarante-six degrés, cinquante minutes ouest (S.46°50' W.), jusqu'au point « 14 ».Du point « 14 », une distance dc vingt-neuf pieds et un dixième (29.1) a été mesurée dans une direction sud quatre-vingt-quatre degrés, vingt-huit minutes ouest (S.84°28' W.), jusqu'au point « 15 ».Du point « 15 », une distance de cent trente-huit pieds et sept dixièmes (138.7) a été mesurée dans une direction nord quarante-trois degrés, douze minutes ouest (N.43°12'W.), jusqu'au point» 7 ».Du point « 7 », une distance de deux mille huit cent soixante-cinq pieds et deux dixièmes (2865.2) a été mesurée dans une direction nord quarante-six degrés, vingt-huit minutes est (N.46°28' E.), jusqu'au point « 6 », point de départ.Ce terrain est borné au nord-est par une partie du lot 183, au sud-est par une partie du lot 194, au sud-ouest par le chemin du Petit Rang St-François, au nord-ouest par le lot 191 et contient, en superficie, quatre cent cinquante-deux mille trois cent un pieds carrés (452,301).1.4 Parcelle « 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 », partie du lot 194: Commençant au point « 16 » du plan ci-joint, lequel point est situé sur la limite nord-est du chemin du Petit Rang St-François avec la ligne de division des lots 194 et 195.Du point « 16 », une distance de cent six pieds et neuf dixièmes (106.9) a été mesurée dans une direction nord quarante-trois degrés douze minutes ouest (N.43°12' W.), jusqu'au point « 17 ».Du point « 17 », une distance de quarante-quatre pieds et neuf dixièmes (44.9) a été mesurée dans une direction nord quinze degrés, quatorze minutes ouest (N.15°14' W.), jusqu'au point « 18 ».Du point « 18 », une distance de quarante-neuf pieds (49.0) a été mesurée dans une direction nord quarante-six degrés, cinquante et une minutes est (N.46°51' E.), jusqu'au point « 19 ».Du point « 19 », une distance de cent dix pieds (110.0) a été mesurée dans une direction sud quarante From point \"9\", a distance of two thousand three hundred ninety-two and seven tenths feet (2,392.7') measured in a direction South forty-six degrees, fifty minutes West (S.46°50' W.), up to a point \"10\".From point \"10\", a distance of two hundred fifteen and two tenths feet (215.2') measured in a direction South seventy-two degrees, thirty-seven minutes West (S.72°37' W.), up to a point \"11\".From point \"11\", a distance of twenty-four and four tenths feet (24.4') measured in a direction South forty-four degrees, eight minutes West (S.44°08' W.), up to a point \"12\".From point \"12\", a distance of ninety-four and four tenths feet (94.4') measured in a direction South twenty-one degrees, twenty-three minutes East (S.21°23' E.), up to a point \"13\".From point \"13\", a distance of two hundred fifteen and two tenths feet (215.2') measured in a direction South forty-six degrees, fifty minutes West (S.46°50' W.).up to a point \"14\".From point \"14\", a distance of twenty-nine and one tenth feet (29.1') measured in a direction South eighty-four degrees, twenty-eight minutes West (S.84°28' W.), up to a point \"15\".From point \"15\", a distance of one hundred thirty-eight and seven tenths feet (138.7') measured in a direction North forty-three degrees, twelve minutes West (N.43°12' W.), up to a point \"7\".From point \"7\", a distance of two thousand eight hundred sixty-five and two tenths feet (2865.2') measured in a direction North forty-six degrees, twenty-eight minutes East (N.46°28'E.), up to a point \"6\", the starting point.This piece of land is bounded on the northeast by a part of lot 193, on the southeast by a part of lot 194, on the southwest by the Petit Rang St-François Road, on the northwest by lot 191 and covers an area of four hundred fifty-two thousand three hundred and one square feet (452,301 sq.ft.).1.4 Parcels \"16, 17, 18, 19, 20, 21, 22\", part of lot 194: Starting at a point \"16\" on the plan attached hereto, which point is located on the northeastern limit of the Petit Rang St.François Road with the dividing line of lots 194 and 195.From point \"16\", a distance of one hundred six and nine tenths feet (106.9') measured in a direction North forty-three degrees, twelve minutes West (N.43°12' W.),up to a point \"17\".From point \"17\", a distance of forty-four and nine tenths feet (44.9') measured in a direction North fifteen degrees, fourteen minutes West (N.15°14' W.), up to a point \"18\".From point \"18\", a distance of forty-nine feet (49.0') measured in a direction North forty-six degrees, fifty-one minutes East (N.46°51' E.), up to a point \"19\".From point \"19\", a distance of one hundred ten feet (110.0') measured in a direction South forty degrees, 2064 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 degrés, cinquante-sept minutes est (S.40°57' E.), jusqu'au point « 20 ».« Du point « 20 », une distance de cent soixante-quatre pieds et six dixièmes (164.6) a été mesurée dans une direction nord quarante-six degrés, cinquante et une minutes est (N.46°51' E.), jusqu'au point « 21 ».Du point « 21 », une distance de trente-cinq pieds et huit dixièmes (35.8) a été mesurée dans une direction sud quarante degrés, cinquante-trois minutes est (S.40°53' E.), jusqu'au point « 22 ».Du point « 22 », une distance de deux cent vingt-neuf pieds et neuf dixièmes (229.9) a été mesurée dans une direction sud quarante-six degrés, vingt-huit minutes ouest (S.46°28' W.), jusqu'au point « 16 », point de départ.Ce terrain est borné au nord-est et au nord-ouest par le résidu du lot 194, au sud-est par une partie du lot 195, au sud-ouest par le chemin du Petit Rang St-François et contient, en superficie, quinze mille quatre cent vingt pieds carrés (15,420).1.5 Parcelle « 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 », partie du lot 195: Commençant au point « 16 » du plan ci-joint, lequel point est situé sur la limite nord-est du chemin du Petit Rang St-François à l'intersection de la ligne de division entre les lots 194 et 195.Du point « 16 », une distance de deux cent vingt-neuf pieds et neuf dixièmes (229.9) a été mesurée dans une direction nord quarante-six degrés, vingt-huit minutes est (N.46°28' E.), jusqu'au point « 22 ».Du point « 22 », une distance de cent quarante-six pieds et trois dixièmes (146.3) a été mesurée dans une direction sud quarante degrés, cinquante-trois minutes est (S.40°53' E.), jusqu'au point « 23 ».Du point « 23 », une distance de cinquante-trois pieds (53.0) a été mesurée dans une direction nord soixante-dix-sept degrés, vingt et une minutes est (N.77°21' E.), jusqu'au point « 24 ».Du point « 24 », une distance de cent soixante-seize pieds et sept dixièmes (176.7) a été mesurée dans une direction sud quarante-trois degrés, trente-neuf minutes est (S.43°39' E.), jusqu'au point « 25 ».Du point « 25 », une distance de trente-trois pieds et cinq dixièmes (33.5) a été mesurée dans une direction sud quarante-six degrés, quatre minutes ouest (S.46° 04' W.), jusqu'au point « 26 ».Du point « 26 », une distance de soixante-seize pieds )76.0) a été mesurée dans une direction nord quarante-deux degrés, quarante minutes ouest (N.42°40' W.), jusqu'au point « 27 ».Du point « 27 », une distance dc cent cinquante pieds et sept dixièmes (150.7) a été mesurée dans une direction sud quarante-quatre degrés, quarante minutes ouest (S.44°40' W.), jusqu'au point « 28».Du point « 28 », une distance de quatorze pieds et trois dixièmes (14.3) a été mesurée dans une direction nord quarante-quatre degrés, quarante minutes ouest (N.44°40' W.), jusqu'au point « 29 ».Du point « 29 », une distance de quatre-vingt-trois pieds et un dixième (83.1) a été mesurée dans une direc- fifty-seven minutes East (S.40°57' E.), up to a point \"20\".From point \"20\", a distance of one hundred sixty-four and six tenths feet (164.6') measured in a direction North forty-six degrees, fifty-one minutes East (N.46° 51' E.), up to a point \"21\".From point \"21\", a distance of thirty-five and eight tenths feet (35.8') measured in a direction South forty degrees, fifty-three minutes East (S.40° 53' E.), up to a point \"22\".From a point \"22\", a distance of two hundred twenty-nine and nine tenths feet (229.9'), measured in a direction South forty-six degrees, twenty-eight minutes West (S.46°28' W.), up to point \"16\" the starting point.This piece of land is bounded on the northeast and on the northwest by the remainder of lot 194.on the southeast by a part of lot 195, on the southwest by the Petit Rang St.François Road and covers an area of fifteen thousand four hundred twenty square feet (15,420 sq.ft.).1.5 Parcels \"16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30\", part of lot 195: Starting at a point \"16\" on the plan attached hereto, said point being located on the northeastern limit of the Petit Rang St.François Road at the intersection of the dividing lines between lots 194 and 195.From point \"16\", a distance of two hundred twenty-nine and nine tenths feet (229.9') measured in a direction North forty-six degrees, twenty-eight minutes East (N.46° 28' E.), up to a point \"22\".From point \"22\", a distance of one hundred forty-six and three tenths feet (146.3') measured in a direction South forty degrees, fifty-three minutes East (S.40° 53' E.), up to a point \"23\".From point \"23\".a distance of fifty-three feet (53.0') measured in a distance North seventy-seven degrees, twenty-one minutes East (N.77° 21' E.), up to a point \"24\".From point \"24\", a distance one hundred seventy-six and seven tenths feet (176.7') measured in a direction South forty-three degrees, thirty-nine minutes East (S.43° 39' E.), up to a point \"25\".From point \"25\", a distance of thirty-three and five tenths (33.5') measured in a direction South forty-six degrees, four minutes West (S.46° 04' W.), up to a point \"26\".From point \"26\", a distance of seventy-six feet (76') measured in a direction North forty-two degrees, forty minutes West (N.42° 40' W.), up to a point \"27 '.From point \"27\", a distance of one hundred fifty and seven tenths feet (150.7') in a direction South forty-four degrees, forty minutes West (S.44° 40' W.), up to a point \"28\".From point \"28\", a distance of fourteen and three tenths feet (14.3') measured in a direction North forty-four degrees, forty minutes West (N.44° 40' W.), up to a point \"29\".From point \"29\", a distance of eighty-three and one tenth feet (83.1') measured in a direction South forty- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n\" 10 2065 tion sud quarante-quatre degrés quarante minutes ouest (S.44°40' W), jusqu'au point « 30 ».Du point « 30 », une distance de deux cent soixante-sept pieds et huit dixièmes (267.8) a été mesurée dans une direction nord quarante-quatre degrés, douze minutes ouest (N.44° 12' VV.) jusqu'au point « 16 », point de départ.Ce terrain est borné au nord-est par une partie du lot 195, au sud-est par la route publique, par une partie du lot 195 et une partie du lot 196, au sud-ouest par une partie du lot 195, par une partie du lot 196 et par le chemin du Petit Rang St-François, au nord-ouest par une partie du lot 194 et contient, en superficie, soixante-neuf mille huit cent quatre-vingt-un pieds carrés (69,881).1.6 Parcelle « 29, 28, 31, 30, partie du lot 196: Bornée au nord-est et au nord-ouest par d'autres parties du lot 195, au sud-est par une partie du lot 196, au sud-ouest par le chemin du Petit Rang St-François; mesurant quatorze pieds et trois dixièmes (14.3) de largeur sur une longueur de quatre-vingt-trois pieds et sept dixièmes (83.7) au sud-est et quatre-vingt-trois pieds et un dixième (83.1) au nord-ouest; contenant, en superficie, mille cent quatre-vingt-neuf pieds carrés (1189).Le tout tel que montré sur le plan ci-joint, préparé par le soussigné portant la date du 21 décembre 1972 et formant un terrain d'une superficie totale de un million, huit cent-soixante-dix-sept mille, cinq cent soixante-dix pieds carrés (1,877,570).Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées auxdits immeubles.Pour être vendu au bureau d'enregistrement division de Bagot, à Saint-Liboire, comté de Bagot, MERCREDI, le VINGT-QUATRIÈME jour d'AVRIL 1974, à QUATORZE heures.Saint-Hyacinthe, 28 février 1974.Le shérif, Michel Laroche.District de Saint-Hyacinthe.56423-0 four degrees, forty minutes West (S.44° 40' W.), up to a point \"30\".From point \"30\", a distance of two hundred sixty-seven and eight tenths feet (267.8') measured in a direction North forty-four degrees, twelve minutes West (N.44° 12' W.), up to point \"16\", the starting point.This piece of land is bounded on the northeast by a part of lot 195, on the southeast by the public road, by a part of lot 195 and a part of lot 196, on the southwest by a part of lot 195, by a part of lot 196 and by the Petit Rang St.François Road, on the northwest by a part of lot 194 and covers an area of sixty-nine thousand eight hundred eighty-one square feet (69,881 sq.ft.).1.6 Parcels \"29, 28, 31, 30\", part of lot 196: Bounded on the northeast and on the northwest by other parts of lot 195, on the southeast by a part of lot 196, on the southwest by the Petit Rang St.François Road; measuring fourteen and three tenths feet (14.3') in width by eighty-three and seven tenths feet (83.7') in depth on the southeast and eighty-three and one tenth feet (83.1') in depth on the northwest; covering an area of one thousand one hundred eighty-nine square feet (1,189 sq.ft.).As the whole appears on the plan attached hereto, prepared by the undersigned, on December 21, 1972 and forming a piece of land covering a total area of one million, eight hundred seventy-seven thousand five hundred seventy square feet (1,877,570 sq.ft).As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to said immoveables.To be sold at the Division of Soulanges Registry Office, in St.Liboire, County of Bagot on WEDNESDAY, the TWENTY-FOURTH day of APRIL, 1974, at TWO o'clock in the forenoon.St.Hyacinthe, February 28, 1974.Michel Laroche, Sheriff.District of St.Hyacinthe.56423 2066 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol- 106, No.10 Errata Errata Municipalité du comté de Terrebonne (Erratum) Veuillez apporter les corrections suivantes à l'avis de vente pour taxes publié dans les éditions du 19 et 26 janvier 1974.Corporation municipale de la paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne Au-dessus du tableau apparaissant au milieu des pages 448 du 19 janvier et 769 du 26 janvier 1974, nous aurions dû indiquer que les descriptions ci-après enu-mérées appartenaient à la « Corporation municipale de la paroisse de St-Louis-de-Terrebonne ».Municipality of the County of Terrebonne (Erratum) Please correct the following notices of sales for taxes published in the issues dated January 19 and 26, 1974.Municipal Corporation of the Parish of St.Louis-de-Terrebonne The heading \"Municipal Corporation of the Parish of St.Louis-de-Terrebonne\" should have appeared in the centre of page 448 of the issue dated January 19 and also in the centre of page 769 of the issue dated January 26, 1974, above the descriptions reprinted hereinafter.Corporation municipale de la paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne Municipal Corporation of the Parish of St.Louis-de-Terrebonne \t\tTaxes\tTaxes\t Noms\tLots\tmunie.\tscol.\tTotal Names\t\tMunie, taxes\tSchool taxes\t Barr, Richard 1.637-19 Bastien, Laurent.283-38 Blain, Mme Edouard.P.450 Un emplacement dans le rang du Cordon sous une partie du lot de terre portant le numéro P.450 aux plan et livre de renvoi officiels de ladite Paroisse de St-Louis de Terrebonne, mesurant 60' de largeur et s'étendant avec cette largeur sur une profondeur de 100 pieds 'de long de la ligne de division entre les lots 450 et 452 de ladite Paroisse St-Louis de Terre-bonne et renfermé dans les bornes suivantes: en front, au sud, par l'emplacement de M.Joseph Langlais, à l'ouest et au nord par le résidu dudit lot P.450 restant au vendeur et à l'est par îe lot No 452, appartenant à M.Benoit Bastien.Bouchard, Alice Etal.P.À prendre ledit emplacement, au nord du terrain appartenant à René Lepage et s'étendant sur une largeur de 60 pieds de long d'une rue projetée par une profondeur de 86 pieds, le tout mesure anglaise et plus ou moins et renfermée dans les limites suivantes: en avant à l'ouest, par une rue projetée; d'un côté au nord, par le terrain appartenant à M.René Lepage; de l'autre côté au sud par le terrain de M.Gonzague Lamothe ou représentant; en arrière à l'est, par la terre de M.Alphonse Bédard.Boucher.Lucien.131-21.Canatelli, François.123-P.27 & P.28 De cette partie du lot portant le numéro 27 de la subdivision officielle du lot originaire du lot 123 (123-P.27) aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de St-Louis de Terre-bonne de forme irrégulière, bornée au nord et au sud par d'autres parties duditlot No 123-27, et à l'est par partie du lot No 123-28, ci-après décrite et à l'ouest par le lot No 123-26, rue mesurant 120 pieds dans sa ligne ouest, 107 pieds dans sa ligne est, 94 pieds dans sa ligne nord et 97 pieds dans sa ligne sud.S 466.06 S 281.78 S 747.84 645.80 1,524.08 2,069.88 18.67 124.28 142.95 An emplacement in Du Cordon Range being part of a plot of land bearing number P.450 on the official plan and in the book of reference for the said Parish of St.Louis-de-Terrebonne, measuring 60' in width and extending, with this same width, over a depth of 100 feet from the dividing line between lots 450 and 462 of said Parish of St.Louis-de-Terrebonne.and bounded as follows: in front, on the south, by the emplacement owned by Mr.Joseph Langlais.on the west and on the north by the remainder of said lot P.450 remaining the property of the vendor, and on the east by lot No.452 belonging to Mr.Benoit Bastien.266.17.90 26.20 44.10 To withdraw said emplacement located north of the piece of land belonging to René Lepage and extending over a width of 50 feet from a planned street, over a depth of 85 feet, the whole in English measure, and more or less, and bounded as follows: In front, on the west, by a planned street; on one side, to the north, by a piece of land belonging to Mr.René Lepage; on the other side, to the south, by the piece of land owned by Mr.Gonzague Lamothe or representatives; in rear, on the east, by the tract of land owned by Mr.Alphonse Bédard.143.82 283.95 427.77 222.37 316.54 638.91 That part of lot bearing number 27 of the official subdivision of original lot 123 (123-P.27) on the official plan and in the book of reference for the Parish of St.Louis-de-Terrebonne, of irregular configuration, bounded on the north and on the south by other parts of said lot No.123-27, on the east by part of lot No.123-28, hereinafter described, and on the west by lot No.123-26, a street measuring 120 feet on its west line, 107 feet on its east line, 94 feet on its north line and 97 feet on its south line. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 2067 Noms Names Lots Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total Canatelli, François.123-P.27 & P.28 .$ 49.89 $ 29.56 $ 79.45 De cette partie du lot portant le numéro 28 de la subdivision officielle du lot originaire du lot 123 (123-P.28), aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de St-Louis de Terre-bonne, de forme irrégulière, bornée au nord et au sud par d'autres parties du lot No 123-28, à l'est par une partie du lot No 123-28, chemin public, et à l'ouest par la partie du lot No 123-27 précédemment décrite, cette partie du lot No 123-28 mesurant 87 pieds en front dans la ligne est, 107 pieds en arrière dans la ligne ouest, sur des profondeurs de 123' dans la ligne nord, et 153 pieds et 5 dixièmes dans la ligne sud, le tout de mesures anglaises et plus ou moins avec toutes bâtisses y érigées.That part of the lot bearing number 28 of the official subdivision of original lot 123 (123-P.28).on the official plan and in the book of reference for the Parish of St.Louis-de-Terrebonne, of irregular configuration, bounded on the north and on the south by other parts of lot No.123-28.on the east by a part of lot No.123^28, a public road, and on the west by part of lot No.123-27 described hereinabove, this part of lot No.123-28 measures 87 feet in front on its east line, 107 feet in rear on its west line, by depths of 123' on its north line and 153 and 5 tenths feet on its south line, the whole in English measure and more or less, with all buildings erected thereon.Chauvette, Alex.282-27.283-19.221.96 8.63 230.48 Domaine Monaco.P.537 .2.262.62 117.43 2,380.05 Un emplacement situé au sud-ouest du Chemin Gascon dans An emplacement located to the southwest of Gascon Road la municipalité de la paroisse de St-Louis de Terrebonne com- in the Municipality of the Parish of St.Louis-de-Terrebonne.posé en partie du lot numéro 537 du cadastre officiel des plan consisting in part, of lot number 537 on the official plan and in et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Louis de Terre- the book of reference of the cadastre for the Parish of St.bonne, de forme irrégulière et mesurant 913 pieds en front au Louis-de-Terrebonne, of irregular configuration, and measuring nord-est, 178.5 pieds au sud-est, 83 pieds au nord-est, 1704,5 913 feet in front on the northeast, 178.5 feet on the southeast, pieds au sud-est, 605.1 pieds au sud-ouest, 683.4 pieds au nord- 83 feet on the northeast, 1704.5 feet on the southeast, 605.1 ouest, 92.3 pieds au sud-ouest, 960 pieds au nord-ouest et con- feet on the southwest, 683.4 feet on the northwest.92.3 feet on tient une superficie d'environ 1.288.165 pieds carrés ou 35 acres the Southwest.960 feet on the northwest and covering an area en mesures anglaises plus ou moins et borné en front au nord est of about 1.288,165 square feet or 35 acres in English measure, par le Chemin Gascon partie du lot 537 et par une partie du more or less, and bounded in front, on the northeast by Gascon lot 537, au sud-est par une partie du lot 537 et par les lots nu- Road, part of lot 537 and by a part of lot 537, on the southeast méros 537-136, 137, 138.139, 140.141, au sud-ouest par partie by a part of lot 537 and by lots numbers 537-136.137, 138.139, du lot 537 et au nord-ouest par partie du lot 537 et les lots 140, 141, on the southwest by part of lot 537 and on the north-numéros 537-1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32, 33, 137, 138 et west by part of lot 537 and lots numbers 537-1, 2, 3, 4, 5, 6, partie du 136.29, 30,31,32,33,137,138 and part of 136.Domaine Monaco.637-51.Domaine Monaco.637-52.Domaine Monaco.637-76.Domaine Monaco.537-146.DonaUon, Jacques.71-4.Dufour, Jean-Claude.534-82.Garry, Ronald & Yvan.533-69.Gauvreau, Marthe Lamontagne.637-4.Hurtubise, J.R.534-32.Hurtubise, J.R.534-35.Hurtubise, J.R.634-37.Hurtubise J.R.534-38.Hurtubise, J.R.634-46.Hurtubise, J.R.834-47.Hurtubise, J.R.534-49.Hurtubise.J.R.534-54.Laneuville, Georges.43-16.Larose, A.537-76.Lauzon, Lorenzo.P.462.Measuring 70 feet in width by 170 feet in depth, the whole in 419\t83\t77\t34\t497.17 437\t46\t83\t40\t520.85 315\t54\t73\t76\t389.30 805\t27\t76\t22\t881.49 159.\t17\t258\t90\t418.07 146\t03\t25\t30\t170.33 23\t51\t74\t.18\t97.69 741.\t48\t473.\t14\t1,214.62 20\t93\t55\t65\t76.58 20\t93\t55\t05\t76.58 20\t.93\t55\t.65\t76.68 20\t93\t55\t.65\t76.58 20.\t93\t55\t65\t76.58 20\t93\t65\t65\t7fj.58 9.\t36\t25.\t39\t34.75 20\t93\t55\t.66\t76.68 105\t96\t649\t04\t755.00 334\t.88\t46\t.92\t381.80 16\t26\to\t25\t18.51 Mesurant 70 pieds de largeur sur 170 pieds de profondeur, le tout mesures anglaises plus ou moins et bornée comme suit: en avant vers le sud par le Chemin St-Roch: en arrière vers le nord, par Dame Rolland Thibault ou représentants, sur partie du même lot d'un côté vers l'ouest, par partie du lot No 461 du même cadastre appartenant à Adrien Bastien et de l'autre côté vers l'est par Dame Gérard Courville ou représentant sur partie du lot No 463 de même cadastre.English measure, more or less, and bounded as follows: in front, towards the south, by St.Roch Road; in rear, towards the north, by the piece of land owned by Mrs.Rolland Thibault or representatives, on part of the same lot on one side towards the west, by part of lot No.461 on said cadastre, said part belonging to Adrien Bastien and on the other side, towards the east, by the piece of land owned by Mrs.Gérard Courville or representatives on part of lot No.463 on said cadastre.Couture, Maurice.265-107.Les immeubles Huro Inc.265-108.Lessard, Michel.537-213.Levasseur, Gaston.131-61.Levasseur, Gaston.131-62 Ouellet, Jean-Paul.537-10 111.80 111.80 363.04 66.88 253.39 506.56 42.91 44.21 26.60 27.35 832.13 371.47 154.71 156.01 389.64 94.23 1,085.62 878.13 206s QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 Taies Taxes Nom, ^ munie.scol.^ Names Munie.School taxes taxes Parent, Fernand.l'un lopin de terre ayant front sur le Chemin Gascon dans St-Louis de Terrebonne, borné au nord-est par le Chemin Gascon, à l'est et au sud et au nord-ouest par d'autres parties du lot 134, à l'ouest par le lot 136 mesurant 160 pieds en front dans la ligne nord-est, 274.1 pieds dans la ligne est, 136.2 pieds dans la ligne sud, 307.9 pieds dans la ligne ouest et 76 pieds dans la ligne nord-ouest, et contenant 45,671 pieds carrés.Poirier, Yvon.133-36.Renaud.Léo & Uxor.265-56 Rivest.Wilfrid.P.342.134.$ 758.58 S 236.74 t 996.32 A plot of land fronting on Gascon Road in St.Louis-de-Terrebonne, bounded on the northeast by Gascon Road, on the east, on the south and on the northwest by other parts of lot 134, on the west by lot 135 measuring 160 feet in front, on its northeast line, 274.1 feet on its east line, 135.2 feet on its south line, 307.9 feet on its west line and 75 feet on its northwest line, and covering an area of 45.671 square feet.77.36 78.35 17.47 39.33 168.69 4.17 116.68 247.04 21.64 Mesurant 60 pieds de largeur par 88 pieds de profondeur mesures anglaises et bornée comme suit: au sud, par un chemin, à l'est par une autre partie dudit lot 342, à l'ouest par M.Albert Bazinet sur le même numéro, et au nord par M.Patrick Lynch.Measuring 60 feet in width by 88 feet in depth, EnriMi measure, and bounded as follows: on the south, by a road, on the east by another part of said lot 342.on the weet by the piece of land owned bv Mr.Albert Bazinet on the same number and on the north by that owned by Mr.Patrick Lynch.St-Louis.George».340-1.St-Louis.Georges.340-8.347-16.Salvaggio, Antonio.636-78.Vanish.Louis.537-74.Les lots ci-dessus font partie du cadastre officiel de la paroisse de St-Louis de Terrebonne.20.20 39.92 6.81 279.63 9.76 60.74 26.13 107.75 29.96 100.66 31.94 387.38 The aforesaid lots are part of the official cadastre for the Parish of 8t.Louis-de-Terrebonne, Commission scolaire de Sainte-Thérèse Dans les tableaux apparaissant en tète des pages 451, 452 et 453 de l'édition du 19 janvier et aux pages 772, 773 et 774 du 26 janvier, nous aurions dû lire: « taxes scolaires au lieu de « taxes municipales *.Ste.Thérèse School Board In the heading of the fifth (5th) column on pp.451, 452 and 453 of the issue dated January 19, and on pp.772, 773 and 774 of the issue dated January 26, for \"Municipal taxes\", please read: \"School taxes\".Corporation municipale de Sainte-Sophie Nous publions de nouveau un texte qui a été publié dans les éditions du 19 et 26 janvier 1974 parce que nous avions omis d'indiquer que les trois descriptions apparaissant sous le dernier tableau des pages 454 et 775 appartenaient à la corporation municipale de Ste-Sophie.Municipal Corporation of Ste.Sophie We are reproducing here a text which was published in the issues dated January 19 and 26, 1974, as there was no indication that the last three descriptions which appeared on pages 454 and 775 should have come under the heading: \"Municipal Corporation of Ste.Sophie\".Corporation municipale de Sainte-Sophie \u2014 Municipal Corporation of Ste.Sophie \tLots\tImmeubles tels que désignés à l'acte enregistré sous le No\t1 'axe( munie.\tTaxes scol.\t Names\t\tImmoveables as described in the deed registered under No.\tMunie, taxes\tSchool taxes\tTotal \t23-11\t396798,\tS 20.63 38.63\tt 19.99 69.20\t1 40.62 97.83 \t23-12.\t\t\t\t \t23-13.23-14.\t\t\t\t \t23-16.\t\t41.64\t46.63\t88.27 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 100- année, n° 10 2069 Noms Names Lots Immeubles tels que désignes à ! acte enregistré sous le No Immoveables as described in the deed registered under No.Taxes munie.M unie, taxe»\tTaxes scol.School taxée\tTotal 346.32 423.90 61.68 66.88 75.77 7.96 88.65\tt 417.36 1.425.66 162.29 188.53 6.99 246.80\t% 763.67 1.849.66 61.68 229.17 264.30 14.95 335.46 12.68\t38.64\t61.12 37.91 49.17 35.83 23.97\t\t37.91 49.17 36.83 23.97 49.17 29.90 6.99 4.00 6.99 4.00 4.00 6.98 8.61\t17.16 14.66\t49.17 29.90 23.14 4.00 6.99 18.66 4.00 5.98 8.61 348.10\t474.19\t822.29 44.09 10.60 15.12\t135.35 19.99 37.88\t179.44 30.69 63.00 74.89 10.17 10.47 12.28\t113.19 6.32 1.42 1.42\t188.08 16.49 11.89 13.70 7.22\t16.26\t23.47 5.79\t6.32\t11.11 20.61 9.41 13.94 5.79 1.03\t1.42 1.42 2.84 21.16\t22.03 10.83 16.78 5.79 22.18 2.09\t4.26\t6.36 2.62 1.03 1.03\t4.26 1.42\t6.88 1.03 2.46 1.56\t22.67\t24.13 1.66\t2.84\t4.40 1.66\t4.84\t6.40 4.2C\t29.67\t33.87 Ouellette.André.Garage Ste-Sophie Ltée.St-Louis, Emile.Loyer.Serge.Fortin.Denis.Piché, Guy.Goch, Joseph.Rakoczy, Joseph.Rank Holding Corp.Rank Holding Corp.Rank Holding Corp.Rank Holding Corp.Rank Holding Corp.Rank Holding Corp.Bryan.Dr.James.Fiedler, Hans J.Dodson, William Vincent, Samuel M.Barnes.William E.Hill.Norman H- Johnson, Albert L.Sarroino.Rudy.Gervais, Roger.Bryan, James A.Stuart, Dame Annette.C.A.Michaud, Syndic.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Clearview Clearview Clearview Clearview Clearview Estates Inc., Estates Inc.Estates Inc.Estates Inc.Estates Inc.EstateB Inc.P.26 26.27.P.86.206-6.P.263 P.269 274-22.P.274 .P.277.P.295 P.296 P.298 P.299 P.319 P.320 P.295.P.295 P.295 .P.295 .P.295 P.296.P.296 .P.316.P.317 318-32.318-33.318-34.P.320 .P.346.367-7.367-8 .367-12.367-10.367-15.367-26.368-14.367-27.368-13.367-49.367-60.367-62.367-58.367-78.367-106.367-108 367-109 367-110.367-112.367-113.367-114.367-119.367-123.367-126.367-126.367-128 367-129.367-132 367-133.367-136.367-137.367-138.367-139.367-140.367-141 367-142.2S0906.412290.337021.346950.410574.377274.250801.203193.316506.368358.387148.387148.387148.387148.334384.334661.387148.387148.371629.374154.372229.372232.381472.293837.394879.379846.401045.372602.325881.408027.322954.322954.322954.322954.322954.322954.322954.322954.322954.322954.322954.322954.322954.322954.322954.322954.322954.322964. 2070 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 Noms Names Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc., Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clejuview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc.Clearview Estates Inc- Clearview Estates Inc.St-Pierre, Guy.8t-Pierre.Guy.Pellerin, Robert.Gaudreault, J.P.Construction Escale Ltée.Bessette, Real.Viau.Robert.Pelletier.Claude.Desjardins, Yvan.Dubé.Paul-Emile.Leblond, Ernest.Asselin.Claude.- Laverdière, Marcel Homeplan Realty Ltd.Homeplan Realty Ltd.8t-Germain, Robert.Bessette, Emile.Chassât.Jacques .Picard.L.A.Picard.L.A- Picard, L.A.Picard, Marjolaine.Picard.Denis.Piché.Jacques.Roy.Real.H.iimu.Rosaire.Thibert.Lucien.Beaupré.Antoine.Babin, Lionel.Chassé, Réal.Laforme, Aurèle.Brillant, Jean.Beauchemin, André.Desjardins.Paul.Lots 367-144.367-145.367-148.367-149.367-163.367-166.367-167.367-161.367-162.367-163.367-165.367-166.367-167.367-169.367-174.367-176.367-177.367-180.367-184.367-186.367-187.367-191.367-193.367-203 .P.369.381-U.381-22.381-23.381-39.381-31.381-42.381-67.381-62.381-67.381-69.367-66.367-124.367-70.367-143.367-182.367-188.P.367.P.367 .P.367.368-27.367-177.368-36.368-60.P.368.P.368 .381-41.P.368 P.368.P.368.P.368.P.368 .P.369.P.368.P.368 .P.368.P.368 .P.368.P.368.P.368 .P.368 .P.368 .P.368.P.369.P.369 P.369 .Immeubles tels que désignés à l'acte enregistré sous le No Immoveables as described in the deed registered under No.322954.322954.322954 322954 322954.322954.322954.322964.322954 322954.322964.322954.322954.322954.322954.322954.322954.405603 370315.370316.370315.370315.370316.370316.370316.370315.370315.382256.588055 364757.396146.406852.399006.400828.400829 403979 406514.405777.331719.366047.414579.416476.388747.301873.406594.327897.314717.426091.347889.318540.374947.398663.398726.399666.399668 399064.400080.400866.330656.365658.363423 Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total 1.56 1.56 1.03 1.03 1.03 2.09 1.03 1.56 1.03 8.65 4.84 2 09 1.38 2.26 1.18 1.18 16.27 6.88 4.75 8.46 4.76 6 95 6.42 1.00 1.56 1.00 2.09 32.38 20.81 27.51 16.96 13.75 33.76 14.28 15 16 13.76 62.43 205.26 166.04 23.31 94.661 116.73 109 94 189.37 116.61 187.64 32.67 116.19 218.02 169.60 26.09 10.76, 10.75| 10.32 10.32 19.38 30.16 22.64 104.69 28.14 12.06 2.84 2.84 1.42 1 42 1.421 4.26 1.42 20.60 1.42 1.421 1.42 2.82 1.42 2.84 1.42 1.42 1.42 34.82 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 30.00 27.14| 40 47 22.86 24.03 22.86 21.44 22.86 11.19 224.75 612.88 181.69 20.98 78.58, 129.96| 107.13 202.43 188.55 733.56 144.33 467.43 269.74 412.01 42.69 14.2» 14 29 14.29 14.29 21.44 282.31 4.40 4.40 2.46 2.46 2.46 6.36 2.46 22.06 2.46 10.07 6.26 4.91 2.80 6.10 2.60 2.60 17.69 41.70 6.17 9.87 6.17 7.37 6.84 2.42 1.66 1.00 2.09 62.38 47.95 67.98 39.82 37.78 66.62 35.72 38.01 24.96 277.18 818.13 337.73 44.29 173.14 246.69 217.07 391.80 305.16 921.20 177.00 683.62 487.76 671.61 68.68 25.04 25.04 24.61 24.61 19.38 30.16 44.08 386.90 28.14 12.06 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 2071 Noms Names Brouillette, Claude.Robert, Yvon.Fortin, Jean-Paul.Cyr, Roger.Verreault, Brigitte.Lambert, Marcel.Lebel, Mme Monique.Savard, Gilles.Guilbeault.Germain.Gauthier, Maurice.Lavergne, Maurice.Brooks, Warner.Lafrance, Jean-Guy.Simard, Réal.Laurier, Julien.Roy, Adrien.Piché, Marcel.Charbonneau, Lieue.Langlois, J.P.Rochon, M.& Mme Marcel Pineault, Fernand.Gatien, Mlle Pauline.Guillemette, Jean M.Roy, Rosaire.Roy, Rosaire.Champeau, Antoinette.Rioux, Lionel.St-Arnaud, Cécile.Ouimet, Gérard.Inconnu.433-3.433-4.433-43.433-44.433-45.433-46.433-47.433-48.439-62.439-64.440-5.P.441.P.441.P.441.500.601.Les lots ci-dessus font partie du cadastre officiel de la de Ste-Sophie.Lots P.369____ P.369____ P.369.P.369____ P.369____ P.369.P.369.P.369.P.369____ 381-37.381-59.P.384.P.389____ P.389____ P.389.P.391____ P.397____ 398-32____ 398-P.99.398-P.102.P.420____ Immeubles tels que désignés à l'acte enregistré sous le No Immoveables as described in the deed registered under No.375364.375975 400085.413339.400222.400234.400612.400830.400868.401273.396991.406859.281714.389760.379259.401810.259882.360208.363130.340763.304354.337280.346661.346708.moins parties vendues / less the parts sold 325544.345307.272440.203913.229583.379529.221216.358S65.Taxes\tTaxes\t munie.\tscol.\t \t\tTotal Munie.\tSchool\t taxes\ttaxes\t S 182.97\tS 234.41\t% 417.38 9.88\t14.29\t24.17 9.88\t14.29\t24.17 23.80\t21.44\t45.24 9.88\t14.29\t24.17 9.88\t14.29\t24.17 9.88\t14.29\t24.17 9.88\t14.29\t24.17 9.88\t14.29\t24.17 29.46\t33.75\t63.21 15.34\t24.52\t39.86 7.71\t\t7.71 45.80\t30.00\t75.80 59.56\t66.30\t125.86 39.18\t30.00\t69.18 34.91\t36.86\t71.77 135.88\t\t135.88 74.90\t101.41\t176.31 41.89\t15.38\t67.27 146.39\t366.74\t513.13 56.01\t98.56\t154.57 14.23\t\t14.23 83.78\t115.76\t199.63 74.91\t41.94\t116.85 127.24\t92.27\t219.51 809.47\t327.65\t1,137.02 104.41\t231.29\t335.70 15.42\t13.98\t29.40 49.59\t24.29\t73.88 6.98\t\t6.98 The lots hereinabove listed form part of the official cadastre for the Parish of Ste.Sophie.Corporation municipale du village de Val-David Municipal Corporation of the Village of Val-David Nous reproduisons un texte qui a été publié dans les éditions du 19 et 26 janvier 1974 aux pages 464 et 785 parce que nous avions omis d'indiquer que les descriptions ci-après énumérées appartenaient à la corporation municipale du village de Val-David.We are reproducing here part of a text published in the issues dated January 19 and 26, 1974, as there was no indication that the descriptions which appeared on page 464 and 785 should have come under the heading: \"Municipal Corporation of the Village of Val-David\".Corporation municipale du village de Val-David \u2014 Municipal Corporation of the Village of Val-David Noms Names\tLots\tRang Range\tCanton Township\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tTotal \tP.3A.\t\t\t\t\t \tP.3B.\t2.\tDoncaster.\t632.67\t97.05\t729.72 Immeubles tels que désignés à l'acte enregistré sous le Immoveables as described in the deed registered under No 314168.No.314168. 2072 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1971,, Vol.106, No.10 Noms Kamts Lots P.39.Fiasche, Giovanni.Immeubles tela que désignés à l'acte enregistré sous le No 304512.Badke.Emile F.26-153 Juodkojis, Pronas.^\"^k Guindon, Mme Fernande Morin.26-293.Watt, Alexander.27-89.Desrochers, Gisèle.P.26.Immeubles tels que désignés à l'acte enregistré sous le No 352747.56273-0 Rang Range 10 Canton Township Morin.Taxes munie.Munie, taxe» Taxes scol.School taxe* Total 262.80 388 24 125.44 Immoveables as described in the deed registered under No.304512.11.10.11.11.10.Morin.Morin.Morin.Morin.Morin.329.63\t 48.82\t42.21 407.87\t91.28 17.78\t18.78 339.17\t235.56 329.63 91.03 499.15 36.56 674.73 Immoveables as described in the deed registered under No.352747.56273 Ville de Boucherville Edition numéro 8 du 23 février 1974 à la page 1575.au tableau de vente 18ème ligne après le paragraphe, la description de l'immeuble aurait dù se lire: « 20-219 » au lieu de: « 19-219 ».56272-o Town of Boucherville In issue number S, dated February 23, 1974, on page 1575, in the 18th line of the list of properties for sale, below the first paragraph, the number of the immoveable should have read: \"20-219\" instead of: \"19-219\".56272 Commission scolaire régionale de la Mauricic Édition numéro 9 du 2 mars 1974 à la page 1778, au tableau d'amortissement 6ième ligne, nous aurions dû lire: « 15 04 1980.$37.000' au lieu de: « 15 04 1980.$34.000.» 56273-0 Municipalité du comté dc Huntingdon Edition numéro 8 du 23 février 1974, pages 1586 et 1587 ainsi que l'édition numéro 9 du 2 mars, pages 1749 et 1750, les noms de Emile Lctouze jusqu'à Mrs.Hazel Sorenson inclusivement auraient dû apparaître comme faisant partie de la municipalité du canton de Hinchinbrookc et non municipalité du canton de Havelock.56273-0 La Mauricie Regional School Board Issue number 9, dated March 2, 1974 on page 1778, of line 6 of the redemption table for: \"15 04 1980.please read: 15 04 1980.$34.000.\" 56273-0 Municipality of the County of Huntingdon In issue numbtr 8, dated February 23, 1974.pages 1586 and 1587, as well as in issue number 9.dated March 2, 1974, pages 1749 and 1750, the list of names beginning with Emile Letouze and ending with Mrs.Hazel Sorenson should have appeared under the heading \"Municipality of the Township of Hinchinbrookc\" and not under \"the Township of Havelock\".56273 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n° 10 2073 INDEX N© 10 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices ASSEMBLÉE NATIONALE NATIONAL ASSEMBLY Convocation de la législature.1966 Convocation of the legislature.1966 Introduction of private bills.'.1967 Présentation de projets de loi privés.19b7 ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES COOPERATIVE ASSOCIATIONS Association coopérative d'aqueduc de Preissac (Formation).1963 Club coopératif de consommation de Ste-Marguerite (Formation).1963 AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Association de Chasse et Pêche de St-Ferdinand Inc.(L.P.).1961 Canadian Road Credit Company, Limited (Loan and Investment Societies Act).1963 Compagnie de crédit Canadian Road, Limitée (La) (Société de prêts et placements).1963 Estate of Louis Marchand (Benefit of Inventory).1962 Estate of Miles Gilbert Walker (Benefit of Inventory).1961 Hôpital Saint-Joseph Artisan (Dissolution).1961 LaSalle, cité-city (Rachat partiel d'obligations-Partial redemption of bonds).1962 Succession Louis Marchand (Bénéfice d'inventaire).1962 Succession Miles Gilbert Walker (Bénéfice d'inventaire).1961 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Demandes: Applications: Altrovitch, Gerald.1959 Ashton, Corinne Jeanne.1957 Belinsky, Nathan.1958 Brodmann, Jacob.1958 Brosseau, George Hector Boynton.1956 Brosseau, George Kenneth Boynton.1956 Cappel, Julius.1958 Coutu, Joseph Mastai Jean Luc.1959 De Jongh Swemer, Enny.1960 Epstein, Mark Brian.1957 Ferron, Marie-Hélène Raymonde Carole.1958 Gelbartowicz, Arnold.1958 Lalonde, Marie Anna Adelaide.1956 Lebel, Marie Berthe Alice.1959 Marie Régina Yvette Violette Taylor Winford.1956 Martel, Lise.1957 Melemetdjian, Léon Vakan.\u2022 1959 Roy, Robert.1957 Sabbag, Fikin Leon.¦ \u2022 \u2022 1957 Taylor, Winford.1956 CAISSES D'ÉPARGNE SAVINGS AND COMMISSION COMMISSION ET DE CRÉDIT CREDIT UNIONS Commission Québec Transport Caisse d'Économie des employés des Hôpitaux des transports du Québec Commission de Sherbrooke (La) (Mod.gr.).2053 Avis de la Commission « proprio motu ».1929 Caisse d'Économie des travailleurs de Marie- Avis de décisions rendues.1929 ville (Mod.gr.).2053 Avis d'introduction de requêtes.1920 Notice \"proprio motu\" by the Commission.1929 No tice of decisions rendered.1929 Notice of submissions applications.1920 2074 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 Places d'affaires Places of business dans la province: in ihe Province: Blue Bird Moving & Storage Ltd.1938 Canada Transport Limited.1936 Diversified Products Trucking Corp.1937 G & H Steel Industries Limited.1936 Gamblin (Theodore D.).1936 Kennedy (Everett) Ltd.1936 Line Haul Ltd.1936 Mack's Transfer Limited.1937 Protrail Rentals Ltd.1937 Ryder Truck Lines Inc.1937 Scott (W.F.& W.D.) Limited.1936 Thompson (J.E.) Transport Inc.1937 Train Trailer Rentals (Québec) Ltd.1937 COMPAGNIES EXTRA-PROVINCIAL ÉTRANGÈRES COMPANIES Changement d'agent: Change of agent: Carter (James B.) Limited.1960 Permis: License: Morin Equipment (1973) Ltd.1960 COMPAGNIES \u2014 COMPANIES LOI DES ACT Abandon Surrender de charte of Charter Alliance Advertising & Applied Arts Inc.1916 Andy Man Limited.1916 Astor Arms Apartments Inc.1916 C.B.F.Investment Corporation.1916 Civic Society of Investments Ltd.(The).1916 Claren Auto Racing Inc.1916 Clover Sales Inc.1916 Cloutier (C.) Inc.1916 Control Equipment Co.Ltd.1916 Courtiers d'Assurance de Duvernay Inc.(Les) 1916 Daveno Upholstering Ltd.1916 Enterprises Agencies Limited.1916 Faitout (Jean) limitée.1916 Fargo Dress Co.Inc.1916 Fibrelite inc.1916 Goubaud de Paris (Québec) inc.1916 Lapan (Frank) Limited.1916 Manik Holdings Inc.1916 McNeil & Coulson (Canada) Ltd.1916 Meehan & Young Co.Limited.1916 Monico inc.1916 Changement de nom Change of name Agence de voyage Solex Jonica ltée.1915 Association des constructeurs d'habitations de Beauharnois-Valleyfield inc.1914 Atelier d'usinage Gagné inc.1914 B.M.S.Industries Ltd.1915 Bateaux Pago de la Mauricie inc.(Les).1914 Biasserie du Passant inc.(La).1914 Carrière Saw-Mills Ltd.1915 Club de golf et de ski « Mountain Acres ».1915 Conseil régional des loisirs de l'Outaouais inc.1915 Constructions Gaston Roy ltée.1915 Consultants J.N.ltée (Les).1915 Distributeurs de produits de l'est inc.(Les) .1915 Eastern Produce Distributors Inc.1915 Écran Sonique ltée.1915 Emboss-O-Prestige Ltd.1915 Emboss-O-Prestige ltée.1915 Entreprises Luc Miclette inc.(Les).1915 Entreprises Y.N.L.ltée (Les).1915 Estriceram Inc.1915 Excel Footwear Mfg.Co.Ltd.1915 Films Jean-Claude Labrecque inc.(Les).1915 Gagné Machine Shop Inc.1914 Goldcop Mines Limited.1915 Industries B.M.S.Ltée (Les).1915 Intergratcd Marine Systems l.M.S.Inc.1915 J.N.Consultants Ltd.1915 Jonica Solex Travel Agency Ltd.1915 Karen Babel Inc.1915 Laval (Lilianne) limitée.1915 Lousel inc.1915 Manoir Vieille Grange Sentinelle du Parc inc.1915 Manufacture de chaussures « Excel » ltée.1915 Mines Goldcop limitée (Les).1915 Mountain Acres Golf &Ski Club.1915 Outaouais Regional Recreation Council Inc.1915 Scierie Carrière ltée.1915 Singer (David) Inc.1915 Systèmes maritimes intègres l.M.S.inc.1915 Ventes Ville-Marie limitée (Les).1915 Ville Marie Sales Limited.1915 Y.N.L.Enterprises Ltd.1915 Demandes d'abandon Applications for de charte Surrender of Charter Auclair (André) & associés inc.1938 Belisle Frères Limitée.1941 C.H.E.Outfitters Inc.1941 Capital Wire Cloth Eastern Limited.1940 Cie de Gestion Gisbec inc.(La).1938 g Inc.1940 .1941 .1938 é-Coeur.1939 .1940 .1939 .1940 .1938 .1938 Morin Heights Holdings Inc.Professional Numismatic (Join Co.R.T.A.Inc.Rapid Gaz Bar Inc.Reliable Investment Inc.Riddell Estates Limited.Société civique de Placements ltée (La) Thouin (R.) ltée.Westside Apartments LUI.1916 Cosmos Printing & Distributi 1916 Écuries Bagatelles ltée (Les).1916 Fogel (A.) Enterprises ltée .1916 Fondation dc l'Hôpital du Sai 1916 Formatrix inc.1916 Gaz industriel du Québec ltée 1916 Geco (Québec) Limited.1916 Gervais Chair & Table Ltd.1916 Gervais Chaise & Table ltée. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106- année, n° 10 2075 Demandes d'abandon Applications for de charte Surrender of Charter (suite) (continued) Libertée ltée (La).1939 Model Auto Electric Ltée.1939 Montreal Importing Limited.1940 Oeuvre des loisirs de la S.S.J.B.de Rivière Blanche inc.1941 Planifonds inc.1939 Québec Industrial Gas Ltd.1939 Seaway Storage Inc.1941 Service S.A.V.E.inc.1941 Divers Miscellaneous AGF Gestion de placements Montréal inc.(Dir.).1944 AGF Montreal Investment Management Inc.(Dir.).1944 Annuaires Trans-Canada (Que.) ltée (Les) (Dir.).1943 Asselin, Benott, Boucher, Ducharme, Lapointe inc.(Dir.).1943 Canterra inc.(Dir.).1944 Corporation des immeubles Multivest (La) (Dir.).1943 Centre Francois-Michelle (Dir.).1944 Co-Matic Inc.(Dir.).1942 Courrier Laval ltée (Dir.).1944 Crawlev & McCraken Company Limited (Dir.).1945 Dialin Crane Service Ltd.(Dir.).1945 Doyon (Fernand) Investments Inc.(Dir.).1945 École Vanguard Québec limitée (Dir.).1944 Ferme Avicole Les Buissons inc.(La) (Dir.).1942 Food Services Limited (Dir.).1945 Grange d'aubaines S.H.inc.(La) (Dir.).1943 Greenshields Ltd.(Dir.).1912 Groupex Distribution Inc.(Dir.).1944 Heist (CH.) ltée (Dir.).1945 Immeubles GBH limitée (Les) (Dir.).1943 Imperial Pants Co.Ltd.(Dir.).1945 International Roman Health Spa Ltd.(Dir.) 1947 Jodoin, Lamarre, Pratte and Associates Inc.(Dir.).1943 Jodoin, Lamarre, Pratte et Associés inc.(Dir.) 1943 K.L.K.inc.(Dir.).1Ô44 Kates Ltd.(Dir.).1945 Mercerie Come Bertrand inc.(Dir.).1946 Metroheat Industries Ltd.(Dir.).1946 Metropolitan Oil & Gas Industries Inc.(Dir.) 1946 Multivest Realties Corporation (Dir.).1943 Murray's Restaurants Limited (Dir.).1946 Nancytcc Ltd.(Dir.).1946 Nancytec ltée (Dir.).1946 Nessbitt, Thomson and Company, Limited (Dir.).1947 Nesbitt, Thomson et compagnie, limitée (Dir.) 1947 Peerless Clothing, Mfg.Company (Dir.)- 1946 Placements Fernand Doyon inc.(Les) (Dir.).1945 Poudres métalliques du Québec, limitée (Les) (Dir.).1947 Québec Metal Powders Limited (Dir.).1947 Sidbec-Feruni inc.(Dir.).1942 Scoop Fashions Inc.(Dir.).1946 Service de Grues Dialin ltée (Dir.) '.1945 Société Triple A inc.(Dir.).1947 Source de santé romaine internationale ltée (Dir.).1947 Sports Experts inc.(Dir.).1947 Trans-Canada Directories (Que.) Ltd.(Dir.).1947 Steel & Stainless Fabricators Limited (Dir.).1947 Unimedia Inc.(Dir.).1942 United Shirt Corp.(Dir.).1942 Vanguard School of Quebec Limited (Dir.) .1944 Vermette & Fils ltée (Dir.).1948 Vermette & Sons Ltd.(Dir.).1948 World Mosaics Inc.(Dir.).1942 Fusion Amalgamation Béton Provincial Ltée.1917 Meubles Radisson (Québec) Limitée (Les).1917 Radisson Furniture (Québec) Limited.1917 Lettres patentes Letters Patent (1\" partie) (Part /) A.D.M.Construction Inc.1905 A.& E.Fire Door Inc.1911 A.J.R.Mechanical Contractors Inc.1906 Acado ltée.1905 Acier Profile S.B.B.inc.1905 Acoustiques Berna inc.1905 Agence de ventes G.M.B.inc.1908 Agence de sécurité Maurice inc.1905 Agences Marines Monarch inc.1905 Agences Marbles ltée (Les).1910 Agrafes Dorson limitée.1905 Aluminium Mirabel inc.1905 Aménagement K.& G.inc.(Les).1910 Aménagements Le Complexe ltée (Les).1905 Ameublement & décor N.Martin inc.1905 Ameublement Floyd inc.1905 Ameublements Lise Montpetit inc.1905 Andrea Hats Ltd.1907 Appartements St-Yves inc.(Les).1905 Arnoldi Tool and Die inc.1905 Assurances Côte & Dionnc inc.1905 Automobiles Gounod inc.1909 B.& E.Cartage (Québec) Ltd.1905 B.H.B.Floor Covering Ltd.1908 B.T.R.Transport Inc.1905 B.V.P.Packers Ltd.1911 Barthom Fashions Inc.1905 Barton Sales Ltd.1912 Beauvais (Max) limitée.1905 Bédard (Madeleine) inc.1906 Belisle (Marcel) inc.1906 Béton du nord ltée.1906 Beutcl, Goodman & compagnie inc.1906 Beutel, Goodman & Company Inc.1906 2076 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 Lettres patentes (1™ partie) (suite) Letters Patent {Part I) (continued) Bisson (Gilles) inc.Blisier Management Services Ltd.Bouchard (Lucier) inc.Boucherie France-Québec inc.(La).Boucherville Muffler Inc.Bousquet and Leroux Construction Inc.Boutique La Baladeuse inc.Boutique Trizia inc.Brasserie Raquette inc.(La).Bridgcman Textile Company Ltd.Brière (M.P.) inc.Brookside Realties Ltd.'.Brucy Stone Inc.Brymar Investments Ltd.Button-Wood Investments Inc.C.E.Construction Inc.C.M.A.World-Wide Furniture Center Inc.C.S.R.Mining & Exploration Ltd.Cables du Saguenay inc.Cam's Tool Renting, Sales and Repairs Ltd.Canadian Apag House Publications Inc.Carrière Mirabel ltée.Cartier Personnel Services Inc.Cassivi (.I.A.) inc.Cenatos Films Inc.Centrale sous-marine Piranhas inc.(La).Centre de mode laurentian ltée.Centre de performance Promotion inc.Centre du camion Radisson inc.Centre mondial des ameublements C.M.A.inc.Chapeaux Andréa ltée (Les).China Dragon Restaurant Inc.Clarilou Inc.Clinique médicale M.D.inc.Clinique médicale Ste-Croix inc.Coffrage Concorde inc.Communication technique et graphique l'Idée Compagnie de brique & pierre Reggina inc.(La).Compagnie de textile Bridgcman ltée.Compagnie de transformation de métaux Montréal ltée.Compagnie d'entreprises Sagman ltée (La).Complex Developments Ltd.Conseillers L.B.C.inc.(Les).Construction A.D.M.inc.Construction Bousquet et Leroux inc.Construction C.E.inc.Construction Choinière inc.Construction Désilex inc.Construction Gaudreau inc.Construction L.& A.Marinclli inc.Construction La Diable inc.Construction Maxi inc.Construction R.L.M.inc.Construction René Bouthillier ltée.Construction Sétagon inc.1906 1912 19C6 1906 1912 1907 1906 1906 19)6 1907 1906 1909 1906 1906 1906 1907 1907 1910 1900 1907 1907 1907 1907 1907 1908 1907 1910 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1911 1907 1911 1911 1905 1910 1905 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1910 1910 1907 1!KI7 1912 Constructions Emilius St-Pierre inc.(Les).1908 Constructions Module inc.'908 Constructions Rénald Biais inc.(Les).1908 Corporation Mirmor.1908 Couvre-planchers B.H.B.ltée.1908 D.B.Entreprises Inc.1906 D.N.D.Masonry Inc.1910 Dac-cal ltée.1908 Danique Sportswear Inc.1908 Danlet Auto Parts Inc.1910 De Maisonneu ve-Kennedy Holdings Limited.1908 Décor & menuiserie Dulac inc.1906 Desilex Construction Inc.1907 Distributeurs W.R.W.inc.(Les).1913 Dorson Staples Limited.:.1905 École nationale de plongée québécoise inc.1906 Éditions Yvan Boulerice inc.(Les).1906 Élie Bottier inc.1906 Émard (Jean) & associés inc.1906 Entrepreneurs en mécanique A.J.R.inc.1906 Entreprises Berdes inc.(Les).190G Entreprises D.B.inc.(Les).1906 Entreprises Galli inc.(Les).1909 Entreprises Guémar ltée (Les).1906 Entreprises Guy Cossette inc.(Les).1906 Entreprises hôtellières des Iles-de-la-Made- leine (E.H.I.M.) inc.(Les).1906 Entreprises Interhol ltée (Les).1906 Entreprises L.A.ltée (Les).1906 Entreprises Léo Ouellet inc.(Les).1906 Entreprises M.A.R.inc.(Les).1907 Entreprises Nordobec inc.(Les).1907 Entreprises Rojo inc.(Les).1908 Entreprises St-Vallier inc.(Les).1908 Entreprises Simon & Gualbert inc.(Les).1908 Entreprises W.Blackburn inc.(Les).1908 Équipement industriel A.& G.inc.1908 Équipements électriques d'autos M.CL.inc.(Les).1908 Esscor Industries Ltd.1909 Eula Administation Services Inc.1912 Excavation Poulin et frères ltée.1908 Ferme Bougama inc.1908 Ferme Défiro inc.1908 Ferme St-Sylvestre inc.1908 Ferrosag Inc.1908 Films Canatos inc.(Les).1908 Fleuriste Michèle Guertin inc.1908 Floyd Furniture Inc.1905 Fondoir Ste-Martine inc.1908 Forest-Ridge Realties Ltd.1909 Fortin, Giguère & Lefebvre inc.1908 Fourniture pour la photographie Perkis ltée.1908 G.M.B.Sales Agency Inc.1908 G.T.Auto Parts Inc.1908 Galeries Cap-Rouge inc.(Les).1908 Galeries Jean-Talon inc.(Les).1908 Galeries Les Saules inc.(Les).1908 Galeries Ste-Marie inc.(Les).1908 Galli Enterprises Inc.1909 Garage Denis Boulanger incorporée.1909 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n\" 10 2077 Lettres patentes Letters Patent (1\" partie) (.Part I) (suite) (continued) Garage Dion & frères inc.1909 Généreux (Marcel) & Associates Inc.1909 Généreux (Marcel) & associés inc.1909 Gestion Guy Gingras inc.1909 Gestion Jacques Gingras inc.1909 Gestion Jules Gingras inc.1909 Gestions De Maisonneuve-Kennedy limitée.1908 Gounod Automobiles Inc.1909 Grand Cidrier (1974) inc.(Le).1909 Grenier Imports Inc.1909 Guemar Enterprises Ltd.1906 Guibonlnc.1909 Habitations B.C.P.(St-Hubert) ltée (Us).1909 Habitations B.C.P.(Ste-Thérèse) ltée (Les).1909 Happy Day Restaurant Ltd.1911 Hôtel Motel Yvon inc.1909 Hôtel-Motel Cha-To-Gai (1974) inc.1909 Huot (P.A.) inc.1909 Immeubles Brookside ltée (Les).1909 Immeubles Forcst-Ridge ltée (Les).1909 Immeubles Jutland ltée (Les).1910 Immeubles Franlou inc.1909 Immeubles Kiamika inc.(Les).1909 Immeubles Koben ltée (Les).1909 Immeubles Lugima inc.(Les).1909 Immeubles Mafitra inc.(Les).1909 Immeubles Matignon ltée (Les).1910 Immeubles Partridge ltée (Les).1909 Immoint Inc.1909 Importation Le Cabochard inc.1909 Importations Grenier inc.(Le).1909 Importations Mcrcel ltée (Les).1910 Importations Raffaelli inc.1911 Imprimerie Loranger inc.(L').1909 Industries de motos tous terrains ltée (Les) .1909 Industries Esscor ltée (Les).1909 Instant Pelleta B.L.Inc.1910 Institut humaniste CI.inc.1909 Interhol Enterprises Ltd.1906 International Winch Inc.1912 Investissements Brymar ltée (Les).1906 Investissements Leigheidi inc.(Les).1910 J.P.Commercial Bindery Inc.1910 Jarry Supermarket Inc.1910 Jutland Realties Ltd.1910 K.& G.Development Inc.1910 Kariton Inc.1910 Koben Realties Ltd.1909 L.B.Tires Inc.1911 L.B.C.Consultants Inc.1910 L.N.Super Market Inc.1912 La Diable Construction Inc.1910 Laurentien Fashion Centre Ltd.1910 Lehouillier (G.) inc.1910 Leigheidi Investments Inc.1910 Location Pelletier inc.1910 Location, vente et réparation d'outils Cam ltée 1907 Lupuyo (Jacques) inc.1910 M.C.L.Auto Electric Equipments inc.1908 M.D.Medical Clinic Inc.1907 M.N.Tile & Terrazzo Ltd.1912 Maçonnerie D.N.D.inc.1910 Maison de publications Apag du Canada inc.1907 Maison du bifteck Real inc.(La).1911 Marcel Importing Ltd.1910 Merinelli (L.& A.) Construction Inc.1907 Maries Agencies Ltd.1910 Marshall Silks Ltd.1912 Matignon Properties Ltd.1910 Matrices et outils Arnoldi inc.1905 Maurice Security Agency Inc.1905 Maxi Construction Inc.1910 Mayoff's (Stan) Restaurant & Delicatessen Inc.1910 Mines & exploration C.S.R.ltée.1910 Mingan Truck Rental Service Inc.1912 Mirabel Aluminum Inc.1905 Mirabel Quarry Ltd.1907 MirmorCorp.1908 Modes Barthom inc.(Les).1905 Module Construction Inc.1908 Monarch Marine Agencies Inc.1905 Morasse (J.-L.) & fils ltée.1910 Morin (André) & fils inc.1910 Nantel et fils ltée.1910 Nordevlnc.1910 Nordobec Enterprises Inc.1907 Palettes instantanées B.L.inc.1910 Perkis Photo Supply Ltd.1908 Pièces d'auto Danlet inc.(Les).1910 Pièces d'auto G.T.inc.(Les).1908 Pièces d'auto S.O.L.inc.(Les).1910 Pièces d'auto Danlet inc.(Les).1910 Pierres Brucy inc.(Les).1906 Placements A.M.A.inc.1910 Placements Lance inc.1910 Placements Platane inc.1906 Placements Rafor ltée (Les).1911 Plantations Lanoraie inc.1911 Pneus L.B.inc.(Les).1911 Porte Coupe-Feu A.& E.inc.1911 Process Metals Co.Montreal Ltd.1911 Productions C.T.ltée (Les).1911 Produits de la boulangerie Van Home inc.(Les).1912 Promotion Performance Center Inc.1907 Provost (Paul) & fils ltée.1911 Publications Le Guide du Citoyen inc.(Les) 1911 Québec National School of Diving Inc.1906 R.B.D.Transport Inc.JWl R.L.M.Construction Inc.1907 Racquet Pub Inc.(The).1906 Raffaelli Imports Inc.1» Rafor Investments Ltd.J91J Real Steak House Inc.» Reggina Brick & Stone Co.Inc.1W1 Reliure commerciale J.P.inc.WM Remorques Val d'Or ltée (Les).1911 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 197!,, Vol.IPG, No.10 Lettres patentes Letters Patent (1\" partie) (Part I) (suite) (continued) Restaurant Bonne Journée ltée.1911 Restaurant & charcuterie Stan Mayoff inc.1910 Restaurant Claire et Jacques inc.1911 Restaurant du dragon chinois inc.1907 Restaurant Fortar inc.1911 Restaurant Relais Deux Cent Dix inc.1911 Restauration Marco ltée.1911 Robenlnc.1911 Robletlnc.1911 Rôtisserie de Levis inc.(La).1911 Roy Data Systems Ltd.1912 Roy (J.D.) Inc.1911 S.B.B.Formed Steel Inc.1905 S.& R.Athletes Management Services Inc.1912 S.O.L.Auto ParU Inc.1910 St-Laurent suspensions d'automobile inc.1911 St-Lawrence Springs Inc.1911 Ste.Martine Rendering Inc.1908 Sabricc limitée.1911 Sagman Enterprises Co.Ltd.1911 Saguenay Lac-St-Jean Saw Inc.1911 Salaison'B.V.P.ltée .1911 Salon Rcjcanne et Serge inc.1911 Scierie Val-des-Bois inc.(La) .1911 Scies du Saguenay Lac St-Jean inc.(Les).1911 Serres du Nord limitée (Les).1912 Service de banquets Brunelle inc.1912 Service dc location de camions Mingan inc.1912 Service de personnel Cartier inc.1907 Service de pneus Dolbeau ltée.1912 Service de transport B.& E.(Québec) ltée .1905 Services administratifs Blisier ltée.1912 Services d'administration athlétique S.& R.inc.-.1912 Services d'administration Eula inc.(Les).1912 Services sanitaires du Saguenay inc.(Les).1912 Setagon Construction Inc.1912 Silencieux Boucherville inc.1912 Société d'aménagement du Mont-Orford (S.A.M.O.) inc.1912 Soies Marshall ltée (Les).1912 Soudure Caplan incorporée.1912 Super marché L.N.inc.1912 Supermarché Jarry inc.1910 Système dc contrôle en administration S.C.A.inc.1912 Systèmes de données Roy ltée (Les).1912 Tapis économique Boulanger inc.1912 Terrassement Deux Étoiles ltée.1912 Terrassement Ferlali inc.1!H2 Therrien (Guy) limitée.1912 Trahan (Michel) inc.1912 Trail-Moto Industries Ltd.1909 Transporama Inc.1912 Transport B.T.R.inc.1905 Transport R.B.D.inc.1911 Treuil international inc.1912 Tuile & terrazzo M.N.ltée.1912 Two Stars Landscaping Ltd.1912 Upel Inc.19J2 Val d'Or Trailers Ltd.1911 Van Home Bakery Products Inc.1912 Ventes Barton ltée (Les).¦¦.1912 Vêtements de sport Daniquc inc.(Les).1908 Vitrerie Brown inc.1912 W.R.W.Distributors inc.1913 Wolkove (Edward B.) and Associates Inc.1913 Wolkove (Edward B.) et associés inc.1913 Lettres patentes Letters Patent (3« partie) Cwl III) Aero-Club du Lac Mégantic Inc.(L').1913 Association de Chasse et de Pêche de St-Fer- dinand Inc.¦ 1961 Association de Motoneigiste Boule de Neige Inc.¦.1913 Association des Locataires des Ilots St-Mar- tin.1913 Association des Propriétaires des Trois Lacs de Stoneham.: \u2022.\u2022 1913 Association des Propriétaires du Lac Morin .1913 Association des Riverains du Lac Aylmer.1913 Association Pétrolière du Québec.1913 Association Provinciale des Enfants Handicapés du Québec Inc.1913 Association Sportive Iberville.1913 Centre Ecologique de la Vallée de La Matapé- dia.1913 Club d'Amateurs d'Oiseaux de Montréal.1913 Club d'Auto-Neige de Westbury Inc.(La).1913 Club de l'Age d'Or, Esprit-Saint.1913 Club de Motocyclette de Sacré-Coeur.1913 Club de Moto les Promeneurs Hardis Inc.1914 Club de Moto-Neige du Lac Otis Inc.1913 Club de Moto-Neige La Coulée Verte.1913 Club de Tir St-Cyprien, Dorchester.1913 Club Optimiste Sainte-Anne des Plaines.1913 Club Social Jolicoeur Inc.1914 Comité dc Coordination des Loisirs de la Région de Richmond.1914 Comité Organisateur des Jeux du Québec Régionaux du Lac Saint-Louis Inc.1914 Comité Paroissial St-Jean-Eudcs Inc.1914 Comité Régional de Développement Culturel Tadoussac Pointe aux Anglais Inc.1914 Cool-Riders Motor-Cycle Inc.1914 Corporation Dynaper.1914 Corps de Clairons Les Elites-Lions de Victo- riaville Inc.(Le).1914 Editions Cheminements Ltée.1914 Fondation Lucas (La).1914 Institut International dc Recherche Rénale., 1914 International Renal Research Institute.1914 Jolicoeur Social Club Inc.1914 Lac Mégantic Flying Club Inc.1913 Lucas Foundation (The).1914 Ordre des Naturothérapeutcs du Québec Inc.1914 Québec Petroleum Association.1913 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106- année, n° 10 2079 Lettres patentes Letters Patent (3* partie) (Part III) (suite) (continued) Radio Amateur Saguenay-Lac-Saint-Jean.1914 Richmond Area Recreation Coordinating Committee.1914 St.Martin Block Tenants Association.1913 Sport Association Iberville.1913 Union Régionale des Gardes Paroissiales du Bas St-Laurent Inc.1914 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Association des Chemins d'Hiver de Rouyn- Noranda(L').1917 Automobiles Raymond Bernier inc.1917 Bernier (Raymond) Auto Inc.1917 Boucherie de France inc.1917 Brochu (Napoléon) inc.1917 Champlain Glass (1969) Inc.1918 Charland Ave.Iron Works Company Ltd- 1917 Club de Golf Le St-Laurent inc.1917 Comcap Factors Inc.1917 Dominion Comb and Novelty Company (The) 1917 Durable Casters and Wheels Manufacturer Limited.1918 Epicerie Latina inc.1917 Everest Woodworks Ltd.1918 Express St-Jean, limitée (L').1918 Fabricant de Roulettes Durables limitée.1918 Facteurs Comcap inc.(Les).1917 Ferme Wilson inc.(La).1918 Gilbecinc.1918 Hôpital St-Lambert (Convalescents).1918 Industrial Life \u2014 Technical Services Inc.1918 Industrielle \u2014 Services Techniques inc.(L') 1918 Kipawa Air Service Inc.1918 Latina Grocery Inc.1917 Machinerie Drummond inc.1918 Maison de la Pizza & du Spaghetti Natalino inc.(La).1918 Menuiserie Everest ltée.1918 Natalino's Pizza & Spaghetti House Inc.1918 National Laser Products Ltd.1918 Pavages de Beauce limitée (Les).1918 Pitsas Pizza Limited.1918 Pizza Pitsas limitée.1918 Placements Carisa inc.(Les).1918 Placements La Rondelle ltée.1918 S.A.F.Equipment Inc.1918 S.A.F.Equipement inc.1918 St.Johns Express Limited.1918 St.Lawrence Golf Club Inc.1917 Société du Verbe Divin.1918 Society of the Divine Word.1918 Textiles du Grand Moulin, Inc.(Les).1918 Vitrerie Champlain (1969) inc.1918 Sièges sociaux Head Offices Airport Delicatessen inc.1951 Association d'entraide Ville-Marie inc.1952 Atelier de Débosselage Santerre Inc.1953 Benoit (Lucien) Construction ltée.1954 Berjo Inc.1948 Bottes de Carton Versatile, Montréal Inc.(Les).1949 Bordeleau & Associates Inc.1953 Bordeleau & associés inc.1953 Budget Fuels Inc.1948 Cantine Pascal inc.1948 530 Sherbrooke Est Limitée.1949 Co-Matic Inc.1951 Deschênes & Fils limitée.1954 Doré (Gérard) inc.1949 Gavsie (R.) & Associates Inc.1953 Groupex Distribution Inc.1954 Huiles Budget Inc.1948 Immeubles GBH limitée (Les).1953 Institut de méditation et de cinétique canadien de Montréal inc.1950 Johl (B.K.) Inc.1954 K.L.K.inc.1955 Knowlton Realty (Québec) Ltd.1950 Lallouz Lumber Company Ltd.1953 Luminaires Clara ltée.1952 Lorida (Québec) inc.1955 Maintenance Ingetec Inc.1955 Mednick Metal Co.Ltd.1951 Metaline Enterprises Inc.1955 Mozart (Sherbrooke) Limited.1952 Mozart (Sherbrooke) limitée.1952 Pejay Construction Inc.1950 Poupart (Raymond) inc.1951 Radio La Sarre inc.1952 Reproduction A.R.T.inc.1949 Riverside Taxi Limited.1951 Sarogex inc.¦ ¦ ¦.: - .1950 Service de batterie Fournier inc.1952 Transport Samson inc.1951 Viau (Bernard J.) inc.1954 Versatile Paper Boxes, Montreal Inc.1949 Curatelle publique Public Curatorship Avis de qualité: Notice of capacity: Gauthier, Mme Roger (née Lise Marin).1972 Gautrey (Marion), Mme Fred.1972 DEMANDES k APPLICATIONS LA LÉGISLATURE TO LEGISLATURE Anjou, ville-town.2055 Communauté urbaine de Montréal.2054 Communauté urbaine de Québec (La).2055 Eaton Regular Baptist Church.2054 Marcoux, (Eugène) Inc.2053 Montreal Urban Community.2054 Québec Urban Community.2055 2080 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 9, 1974, Vol.106, No.10 LIQUIDATION DES WINDING-UP COMPAGNIES \u2014 Loi de la ACT Association coopérative des camionneurs de Girardville.1978 MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales: Municipal Affairs: Bireau de révision du district de Québec (Thetford-Mines).1966 Board of revision of the district of Québec (Thetford-Mines).1966 Institutions Financial financières.Institutions compagnies Companies et coopératives and Cooperatives Assurances: Insurance: Gamble Alden Life Insurance Company (F usion-A mulgamat ion).1970 Grain Insurance and Guarantee (Permis- License).1971 Richesses narureUes Natural Resources Commission hydroélectrique (Révocation).1967 Compagnie Québec Power (Révocation).1967 Québec Hydro-Electric Commission (Revocation).1967 Québec Power Company (Revocation).1967 Terres et forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Babel, canton-township.1968 Magog, canton-township.1968 Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, par.1968 Saint-Jérôme, par.1968 Saint-Jérôme, par.1968 Saint-Joseph-de-Chambly, par.1969 Saint-Martin, par.1969 Sainte-Agathe-des-Monts, par.1969 Sainte-Agathe-des-Monts, par.1969 Sainte-Agathe-des-Monts, par.1969 Sainte-Marguerite, par.1970 Sainte-Marguerite, par.1970 PROCLAMATIONS PROCLAMATIONS Coming into force of the official cadastre of a part of the township of Letellier, situated in the registration division of Sept-Iles.1974 Coming into force of the official cadastre of a part of the townsnip of Rivière-au-Tonnerre, situated in the registration division of Sept-Iles.1972 Coming into force of the official cadastre of a part of the township of Vauquelin, situated in the registration division of Abitibi.1975 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du canton de Letellier, située dans la division d'enregistrement de Sept-lles.1974 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, située dans la division d'enregistrement de Sept-îles.1972 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du canton de Vauquelin, située dans la division d'enregistrement d'Abitibi.1975 Régie de l'électricité et du gaz Gaz du Québec, inc.(Requête-Application) Electricity and Gas Board 1971 RENSEIGNEMENTS SUR COMPANIES LES COMPAGNIES INFORMATIONS ACT Révocation de dissolution: Revocation of dissolution: Club Belle Nature Inc.1955 Services de Santé Health Services et services sociaux and Social Services Loi sur les Act Centre d'Accueil dc Gatineau (L.P.).1964 Centre d'Accueil dc St-Bcnoit (L.P.).1964 Centre Hospitalier de Buckingham (L.P.S.).1965 Centre Hospitalier St-Eusèbe (L.P.).1964 Centre Rosalie Jette (L.P.).1965 Hôtel-Dieu d'Amos (L.P.S.).1965 Pavillon d'Argenteuil (L.P.).1965 Pontiac Home For the Aged (L.P.).1966 Société d'habitation Québec Housing du Québec Corporation Municipal Housing Bureau of Saint-Lambert (L.P.).1977 Municipal Housing Bureau of Sainte-Brigide (L.P.).1977 Municipal Housing Bureau of Sullivan (L.P.) 1978 Office Municipal d'habitation de Saint-I.au- bert(L.P.).1977 Office Municipal d'habitation de Sainte-Brigide (L.P.).1977 Office Municipal d'habitation de Sullivan (L.P.).1978 SOUMISSIONS \u2014 TENDERS \u2014 demandes de Requests for Aima, cité-city.1982 Arthabaska, ville-town.1984 De l'Estrie, c.s.r.-r.s.b.1987 Farnham, cité-city.1979 La Mauricie, c.s.r.-r.s.b.(Erratum).2072 Salaberry, c.s.r.-r.s.b.1991 St-Jean-de-la-Lande, par.1993 Saint-Jovite, village.1986 Tremblay, canton-township.1980 Vaudreuil-Soulanges, c.s.r.-r.s.b.1989 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1974, 106' année, n\" 10 VENTES SALES Par Shérifs By Sheriffs Joliette Joliette Aeterna-Vie, Compagnie d'assurance vs Patsy DiFabio.2056 Montréal Montreal Dimanche Matin (1967) ltée (Le) r* Les maisons Tradition du Québec ltée.2056 Individual Investment Corp., Brothers Trading Corp., and Ace Mortgage Corp.H Marier.2056 Québec Québec Heller-Natofin Ltd.vs Franco & al.2059 Page limitée vs Bradette.2060 2081 Saint-François Saint-François Lafleur électrique inc.vs Gagné et al.2060 Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe Construction St-Paul ltée vs Sanair Inc.et al.2061 Taxes Taxes Argenteuil, comté-county.2007 Boucherville, ville-town (Erratum).2072 Dorchester, comté-county.2003 Farnham, cité-city.1995 Huntingdon, comté-county (Erratum).2072 Mirabel, ville-town.2004 Lorraine, ville-town.1996 Pontiac, comté-county.1997 Saguenay, comté-county.1995 Terrebonne, comté-county (Erratum).2066 SOMMAIRE SUMMARY Assemblée nationale.1966 Associations coopératives, Loi des.1963 Avis divers.-¦.1961 Caisses d'épargne et de crédit.2053 Changement de nom.Loi du: Demandes.1956 Commission des transports du Québec.1919 Compagnies, Loi des: Abandon de charte.1916 Changement de nom.1914 Demandes d'abandon de charte.1938 Divers.1942 Fusion.1917 Lettres patentes (In partie).1905 Lettres patentes (S\" partie).1913-1961 Lettres patentes supplémentaires.1917 Sièges sociaux.1948 Compagnies étrangères: Agent.I960 Permis.I960 Curatelle publique.1972 Demandes k la Législature.2053 Liquidation, Loi de la.1978 Ministères: Affaires municipales.1966 Institutions financières, compagnies et coopératives: Assurances.c-?Richesses naturelles.1967 Terres et forêts.1968 Proclamations.1972 Régie de l'électricité et du gaz.1971 Renseignements sur les compagnies: Révocation de dissolution.1955 Services de santé et services sociaux.1964 Société d'habitation du Québec.1977 Soumissions.1979-2072 Applications to Legislature.2053 Change of Name Act: Applications.1956 Companies Act: Amalgamation of companies.1917 Applications for surrender of charter.1938 Change of name.1914 Head offices.1948 Letters patent (Pari I).1905 Letters patent (Part III).1913-1961 Letters patent supplementary.1917 Miscellaneous.1942 Surrender of charter.1916 Companies Information Act: Revocation of Dissolution.1955 Cooperative Associations Act.1963 Departments : Financial Institutions, Companies and Cooperatives: Insurance.1970 Lands and Forests.1968 Municipal Affairs.1966 Natural Resources.1967 Electricity and Gas Board.1971 Extra-Provincial Companies Act: Agent.1960 License.1960 Health Services and Social Services.1964 Miscellaneous Notices.1961 National Assembly.1966 Proclamations.1972 Public Curatorship.1972 Québec Housing Corporation.1977 Québec Transport Commission.1919 Sales: By Sheriffs: Joliette.2056 Montreal.2056 Québec.2059 Ventes : Par shérifs: Joliette.J» Montréal.2056 Québec.20ôa Saint-François.2060 Saint-Hyacinthe.20bl Pour taxes .1995-2066 St.François.2060 St.Hyacinthe.2061 For taxes.1995-2066 Savings and Credit Unions.2053 Tenders.1979-2072 Win ding-Up Act.1978 "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.