Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 15 (no 37)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1951-09-15, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 83, N° 37 2487 Vol.83, No.37 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provinclal government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 15 septembre 1951 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4e Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, September 15th, 1951 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the.second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe.Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 2488 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 septembre 1961, Tome 83, N° 37 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion i le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.29088 \u2014 1-52 Lettres patentes receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents i>er agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation : 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SL per dozen.Subscriptions: S7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.29088 \u2014 1-52 Letters Patent Alaska Quilting Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-huit juin 1951, constituant en corporation: Eugène Reichbach, marchand, Sureka Wasserman, secrétaire, et Anne Gabbe, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de laine, coton, soie, nylon, plastique, fils, vêtement, ficelle, sous le nom de \"Alaska Quilting Corporation\", avec un capital de $40,000 divisé en 700 actions ordinaires de $20 chacune, et 1300 actions privilégiées de $20 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30879 C.E.CANTIN.Alaska Quilting Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Proyince of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-eighth day of June, 1951, incorporating: Eugène Reichbach, merchant, Sureka Wasserman, secretary, and Anne Gabbe, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wool, cotton, silk, nylon, plastic, yearns, clothing, twines, under the name of \"Alaska Quilting Corporation\", with a capital stock of $40,000.divided into 700 common shares of $20.each, and 1300 preferred shares of $20.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30879-o Acting Deputy Attorney General. QliEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 15th, 1951, Vol 88, No.37 2489 Arthur Guyot & Fils Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept juin 1951, constituant en corporation: Arthur Guyot, industriel, Hélène Guyot, secrétaire, Pierre Guyot, gérant, Yvon Guyot, technicien, et Rosaire Lamoureux, contramaître, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers et négociants d'ornements d'église, sous le nom de \"Arthur Guyot & Fils Limitée\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1031, rue Rachel Est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30879-o C.E.CANTIN.Associated Real Estate Appraisers Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf juin 1951, constituant en corporation: Jean Marier, secrétaire, Béatrice Pelletier, sténographe, Luigi Pascale, aegnt de voyage tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivats: Exercer le commerce comme estimateurs et évaluateurs, sous le nom de \"Associated Real Estate Appraisers Inc.\", avec un capital de $10,000 divisé en 2,000 actions de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera au numéro civique 435 Avenue Elm, dans la cité de West-mount, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30879 C.E.CANTIN.Crépeault & Fradette Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date* du vingt-neuf juin 1951, constituant en corporation: Eugène Crépeault, agent d'assurances, Charles-Henri Crépeault, plâtrier, tous deux de Giffard, et Jean Baptiste Fradette, plâtrier, de Beauport, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs en construction, sous le nom de \"Crépeault & Fradette Limitée\", avec un capital de $20,000 divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 41, rue de l'Orphelinat, à Giffard, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30879-o C.E.CANTIN.Employing Printers' Association of Montreal Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Arthur Guyot & Fils Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of June, 1951, incorporating: Arthur Guyot, industrialist, Hélène Guyot, secretary, Pierre'Guyot, manager, Yvon Guyot, technician and Rosaire Lamoureux, foreman, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturers and dealers in church ornaments, under the name of \"Arthur Guyot & Fils Limitée\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1031 Rachel St.East, Montreal, judicial distirct of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30879 Acting Deputy Attorney General.Associated Real Estate Appraisers Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of June, 1951, incorporating: Jean Marier, secretary, Béatrice Pelletier, stenographer, Luigi Pascal, travel agent, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as appraisers and valuators, under the name of \"Associated Real Estate Appraisers Inc.\", with a capital stock of $10,000.divided into 2,000 shares of $5.each.The head office of the Company will be at civic No.435 Elm Avenue, in the City of Westmount, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30879-o Acting Deputy Attorney General.Crépeault & Fra'dette Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of June, 1951, incorporating: Eugène Crépeault, insurance agent, Charles-Henri Crépeault, plasterer, both of Giffard and Jean Baptiste Fradette, plasterer, of Beauport, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on business as building contractors, under the name of \"Crépeault & Fradette Limitée\", with a capital stock of $20,000 divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 41 de L'Orphelinat street, Giffard, judicial district of Québec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30879 Acting Deputy Attorney General.Employing Printers' Association of Montreal Inc.Notice is hereby given that under the provisions of Part DU of the Quebec Companies' Act, 2490 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 septembre 1951, Tome 83, N° 37 Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept juin 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Oswald Scott Markham, Thomas Edward Roberts, Frederic Alan Smith, John Stuart Miller, Frederick Best, Robert Thomas Birch, Joseph Goodson, David Albert McLean et Lynn Alexander Wat-ters, tous imprimeurs, des cité et district judiciaires de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir et protéger les intérêts des membres de l'industrie de l'imprimerie, sous le nom de \"Employing Printers' Association of Montreal Inc.\" Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district, judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30879 C.E.CANTIN.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of June, 1951.incorporating without share capital: Oswald Scott Markham, Thomas Edward Roberts, Frederic Alan Smith, John Stuart Miller, Frederick Best, Robert Thomas Birch, Joseph Good-son, David Albert McLean and Lynn Alexander Watters, all printers, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To advance and protect the interests of the members of the Printing industry, under the name of \"Employing Printers' Association of Montreal Inc.\" The amount to which the value of the immoveable property which the Corporation may possess, is to be limited, is $25,000.The head office of the Corporation will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-seventh day of June, 1951.C.E.CANTIN.30879-o Acting Deputy Attorney General.François Bédard Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux juin 1951, constituant en corporation: François Bédard, entrepreneur général, Marins Bédard, commis, et Elphège McClish, employé civil, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeur et entrepreneur, sous le nom\" de \"François Bédard Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30879-e C.E.CANTIN.François Bédard Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of June, 1951, incorporating: François Bédard, general contractor, Marius Bédard, clerk and Elphège McClish, civil employee, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on business as builder and contractor, under the name of \"François Bédard Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorey General, this twenty-second day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30879 Acting Deputy Attorney General.Golden Valley Granite Co.Ltd.(Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi -des compagnies Minières de Québec, il a été accordé par le Lieutennat-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six juin 1951, constituant en corporation : Jean-Baptiste Trottier, prospecteur, Aldéric Collin, contracteur, Gérard Nadeau, comptable, Désiré Chabot, huissier, et Lucien Oucllet, comptable, tous de Val d'Or, district judiciaire d'Abi-tibi, pour les objets suivants: Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais; Faire toutes opérations qui consistent à miner, développer, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque autre manière que ce soit, le sol ou les terres, les roches ou les pierres, dans le but d'en extraire des minreais quelconques; donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de \"Golden Valley Granite Co.Ltd.\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de $400,000 divisé en 4,000 actions de $100 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé par eux à la compagnie pour ses actions.Golden Valley Granite Co.Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Compagnies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of June, 1951, incorporating: Jean-Baptiste Trottier, prospector, Aldéric Collin, contractor, Gérard Nadeau, accountant, Desire Chabso, bailiff and Lucien Ouellet, accountant, all of Val d'Or, judicial district of Abitibi, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals; Carry on all operations by which the soil, earth, rocks and stones may, for the puropse of extracting any minerals whatsoever, be mined, dug, raised, washed, cradled, smelted, refined, crushed or treated in any manner; render such minerals merchantable by any means whatsoever; and sell or otherwise dispose thereof, under the name of \"Golden Valley Granite Co.Ltd.\" (No Personal Liability), with a capital stock of $400,000 divided into 4,000 shares of $100 each.The shareholders shall incur no personal liability in excess of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September loth, 1951, Vol.83, No.37 2491 Le siège social de la compagnie sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30879-o C.E.CANTIN.Granby Lumber & Supply Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six juin 1951, constituant en corporation: J.-Emile Maheu, Aurélien Noel, comptables, et .1.-Alexandre Babin, commerçant, de Granby, district judiciaire de Bedford, et les deux premiers des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: \u2022 Exercer le commerce de bois et de matériaux de construteion, sous le nom de \"Granby Lumber & Supply Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune, et en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30879-o C.E.CANTIN.Green Valley Lodge Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux juin 1951, constituant en corporation: Germain Bock, avocat et conseil en loi du Roi, de Laval-sur-lc-Lac, Jean Beauregard et Louis-Philippe Taschereau, avocats, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôtelier, sous le nom de \"Green Valley Lodge Inc.\", avec un caiptal de $40,000 divisé en 40.000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Henri de Mascouche, district judiciaire de Terre-bonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30879-o C.E.CANTIN.Greeting Cards Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six juin 1951, constituant en corporation: Issie Koch, libraire, Harold S.Freeman, B.Benno Cohen, avocats, tous de la cité de Montréal et H.J.Zaitlin, avocat, de la cité de d'Ou-tremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et le négoce de toutes sortes de cartes postales et jouets, ornements et nouveautés, sous le nom de \"Greeting Cards Limited\", avec un capital de $75,000 divisé en 750 actions ordinaires de $50 chacune et 750 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.The head office of the company will be at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30879 Acting Deputy Attorney General.Granby Lumber & Supply Ltd.Notice is heerby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of June, 1951, incorporating: J.Emile Maheu, Aurélien Noel, accountants and J.Alexandre Babin, dealer, of Granby, judicial district of Bedford and the two first petioners of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business and deal in lumber and building supplies, under the name of \"Granby Lumber & Supply Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 preferred shares of a par value of $100 each and into 200 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30879 Acting Deputy Attorney General.Green Valley Lodge Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Comapnies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day ot June, 1951, incorporating: Germain Bock, advocate and King's Counsel, of Laval-sur-le-Lac, Jean Beauregard and Louis Philippe Taschereau, advocates, both of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as hotel keeper, under the name of \"Green Valley Lodge Inc\"., with a capital stock of $40,000 divided into 40,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Saint-Henri de Mascouche, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of June, 1951.C.E.CANTIN.30879 Acting Deputy Attorney General.Greeting Cards Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of June, 1951, incorporating: Issie Koch, stationer, Harold S.Freeman, B.Benno Cohen, advocates, a all of the City of Montreal, and H.H.Zaitlin, advocate, of the City of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and deal in all kinds of greeting cards and toys, ornaments and novelties, under the name of \"Greeting Cards Limited\" with a capital stock of $75,000.divided into 750 common shares of $50.each and 750 preferred shares of $50.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal. 2492 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 septembre 1951, Tome 83, JV° 37 Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30879 C.E.CANTIN.L'Association Catholique d'Études Bibliques au Canada Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois juillet 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Les Révérends Pères Arthème Tétrault, S.J., professeur d'Écriture Sainte, des cité et district judiciaire de Montréal, Adrien Brunet, O.P., professeur d'Écriture Sainte, de la cité d'Ottawa, Georges Bulteau, P.S.S., des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir les études bibliques au Canada, sous le nom de \"L'Association Catholique d'Etudes Bibliques au Canada\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $25,000.' Le siège social de l'Association sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juillet 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30879-o C.E.CANTIN.L'élégante Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze juin 1951, constituant en corporation: Sydney Lazarovitz, François Veilleux, avocats, et Jeanne d'Arc Leclerc, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de marchandises sèches et des lingeries, garnitures de maison, ameublement, chaussures de toutes sortes, bijoux, articles de toilette, produits de beauté, bibelots, sous le nom de \"L'Elétancte Inc.\", avec un capital de $20,-000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 315^, rue Saint-Joseph, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le quinze juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30879-n C.E.CANTIN.L'Institut des Oblates Bénédictines de Ville-Marie Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compangies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf juin 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Clo-tilde Mathys, Georgette Plineault, ouvrières sociales, de Montréal, et Louise Lefebvre, bibliothécaire, d'Outremont, toutes du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Travailler au renouveau chrétien, sous le nom de \"L'Institut des Oblates Bénédictines de Ville-Marie'.' Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $100,000.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth dav of June, 1951.C.E.CANTIN, 30879-o Acting Deputy Attorney General.L'Association Catholique d'Études Bibliques au Canada Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of July, 1951, incorporating without share capital: The Reverend Fathers Artheme Tetrault, S.J., professor of Holy Scripture, of the city and judicial district of Montreal, Adrien Brunet, O.P.professeur of Holy Scriture, of the city of Ottawa, Georges Bulteau, P.S.S., of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To promote biblical studies in Canada, under the name of \"L'Association Catholique d'Études Bibliques au Canada\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head office of the Society will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of July, 1951.C.E.CANTIN, 30879 Acting Deputy Attorney General.L'élégante Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fiftheenth day of June, 1951, incorporating: Syndney Lazarovitz, François Veilleux, advocates and Jeanne d'Arc Leclerc, stenographer, all of the city and judicial district of Quebec, for Ihe following purposes: To deal in dry goods and lingerie, house furnishings, furniture, shoes of all kinds, jewellery, toilet articles, beauty products and notions, under the name of \"L'Élégante Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at 315]^ St-Joseph street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, tins fifteenth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30879 Acting Deputy Attorney General.L'Institut des Oblates Bénédictines de Ville-Marie Notice is hereby given that, under the provisions of Part HI of the Quebec Companies Act, -letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of June, 1951, incorporating without share capital: Clotilde Mathys, Georgette Pineault, social workers, of Montreal and Louise Lefebvre, librarian, of Outremont, all the judicial district of Montreal, for the following purposes: To promote the renewal of Christianity, under the name of \"L'Institut des Oblates Bénédictines de Ville-Marie\".The amount to which the annual revenue from the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 15th, 1951, Vol 83, No.37 2493 Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Date du bureau du Procureur général, le vingt-neuf juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant.30879-o C.E.CANTIN.Nouvelle Pulpwood Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huit juin 1951, constituant en corporation- William John West, Herbert Hiram Gunter avocats, et Howard Hovey Hagerman, gérant, tous de la cité de Fredericton, comté de York, province du Nouveau-BrunswickV pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à produire du bois de pulpe et du bois de construction, agir comme marchands et courtiers de bois de charpente et propriétaires de scierie, sous le nom de \"Nouvelle Pulpwood Limited\", avec un capital de $40,000 divisé eu 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Carleton, district judiciaire de Bonaventure.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30879 C.E.CANTIN.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of June, 1951.CE.CANTIN.30879 Acting Deputy Attorney General.Nouvelle Pulpwood Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of June, 1951, incorporating: William John West, Herbert Hiram Gunter, barristers-at-law, and Howard Hovey Hagerman, manager, all of the City of Fredericton, County of York, Province of New Brunswick, for the following purposes: To carry on the business of pulpwood and lumber operators, timber merchants and brokers and saw-mill proprietors, under the name of \"Nouvelle Pulpwood Limited\", with a capital stock of $40,000.divided into 4,000 shares of $10.each.The head office of, the Company will be at Carleton, Judicial District of Bonaventure.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-eighth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30879-o Acting Deputy Attorney General.Vallej field Express Limitée Valleyfield Express Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept juin 1951, constituant en corporation: Antonio Patenaude, J.-Paul Chatel, marchands, Lionel Cossette.avocat, tous de la cité de Salaberry de Valleyfield, district judiciaire de Beauharnois, pour les objets suivants: Faire le1 commerce général de transport et d'entreposage, de garagiste, sous le nom de \"Va-leyfield Express Limitée\" \u2014 \"Valleyfield Express Limited\", avec un capital de $50.000 divisé en 5.000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Salaberry de Valleyfield, district judiciaire de Beauharnois.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant.30879-o C.E.CANTIN.Valleyfield Express Limitée Valleyfield Express Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of June, 1951, incorporating: Antonio Patenaude, J.Paul Chatel, dealers, Lionel Cossette, advocate, all of the city of Salaberry de Valleyfield judicial district of Beauharnois, for the following puq)oses: To carry on the business of transportation and warehousing in general, under the name of \"Valleyfield Express Limitée\" \u2014 \"Valleyfiled Express Limited\", with a capital stock of $50,000 divided into 5,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Salaberry de Valleyfield, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30879 Acting Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent American Paper Box Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 21 août 1951, à la compagnie \"American Paper Box Co.Limited\", ratifiant son règlement \"E\" augmentant son capital de $199,-000 à $298,900 par la création de 999 actions ordinaires additionnelles de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 21 août 1951.L'Assistant-procureur général, 30880 L.DÉSILETS.American Paper Box Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of August, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"American Paper Box Co.Limited\", ratifying its By-Law \"E\" increasing its capital stock from $199,000 to $298,900 by the creation of 999 additional common shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this 21st dav of August, 1951.^ L.DÉSILETS, 30880-o Deputy Attorney General. 2494 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 septembre 1951, Tome 83, N° 37 Compagnie d'Immeubles St.Pierre Limitée St.Pierre Realties Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accodré par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 27 août 1951, à la compagnie \"Compagnie d'Immeubles St.Pierre Limitée \u2014 St.Pierre Realties Company Limited\", ratifiant: 1°) son règlement spécial \"B\" modifiant les dispositions des lettres patentes de la manière indiquée dans ce règlement; 2°) son règlement spécial \"C\" diminuant le capital autorisé de la compagnie de $200,000 à $50,000 par l'annulation de 1,500 actions ordinaires non-émises d'une valeur au pair de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 27 août 1951.L'Assistant-procureur général, 30880 L.DÉSILETS.Compagnie d'Immeubles St.Pierre Limitée St.Pierre Realties Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 27th day of August 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Compagnie d'Immeubles St.Pierre Limitée \u2014 St.Pierre Realties Company Limited\", ratifying: 1.) its Special By-law \"B\" modifying the provisions of the letters patent in the manner set forth in such by-law: 2.) its Special By-Law \"C\" reducing the authorized capital stock of the company from $200,000 to $50,000 by the cancellation of 1,500 unissued common shares of the par value of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this 27th day of August, 1951.L.DÊSILEiS, 30880-o Deputy Attorney General.Forster, McGuire & Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des.compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 24 août 1951, à la compagnie \"Robert Forster & Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 5 octobre 1949, changeant son nom en celui de \"Forster, McGuire & Company Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le 24 août 1951.L'Assistant-procureur général, 30880 L.DÉSILETS.O.Chalifour, Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplé-mentairse, en date du 15 août 1951, à la compagnie \"O.Chalifour, Incorporée\", ratifiant un règlement augmentant son capital de $150,000 à $250,000, par la création de 600 actions privilégiées classe A de $100 chacune et de 400 actions privilégiées classe B de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énoncés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 15 août 1951.L'Assistant-procureur général, 30880-o L.DÉSILETS.Regalco Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 24 août 1951, à la compagnie \"Les Galeries Mont-Royal Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 22 juillet 1947, changeant son nom en celui de \"Regalco Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le 24 août 1951.L'Assistant-procureur'général, 30880 L.DÉSILETS, Alphonse Gratton Inc.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Forster, McGuire & Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of August, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Robert Forster & Company Limited\", incorporated by letters patent dated October 5th, 1949, changing its name to that of \"Forster, McGuire & Company Limited\".Dated at the office of the Attorney General, this 24th day of August, 1951.L.DÉSILETS, 30880-o Deputy Attorney General.O.Chalifour, Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the fifteenth day of August, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"O.Chalifour, Incorporée,\" ratifying a by-law increasing its capital stock from $150,000 to $250,000 by the creation of 600 Class A preferred shares of $100 each and 400 Class B preferred shares of $100 each, bearing the rights, restrictions and privileges set forth in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, , this fifteenth day of August, 1951.L.DÉSILETS, 30880 Deputy Attorney General.Regalco Limited Notire is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of August, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Les Galeries Mont-Royal Limitée\", incorporated by letters patent dated July 22nd, 1947, changing its name to that of \"Regalco Limited\".Dated at the office of the Attorney General, this 24th day of August, 1951.L.DÉSILETS, 30880-o Deputy Attorney General.Alphonse Gratton Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary let- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 15th, 1951, Vol.88, No.87 2495 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 24 août 1951, à la compagnie \"Alphonse Gratton Inc.\", ratifiant son règlement N° 6 portant son capital-actions autorisé de 820,000 à $120,000, par la création de 1,000 actions privilégiées nouvelles de $100 chacune, sujettes aux droits et restrictions indiqués audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 24 août 1951.L'Assistant-procureur général, 30903-o L.DÉSILETS.Najeeb Lawand & Sons, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 24 août 1951 à la compagnie \"Najeeb Lawand & Sons, Limited\", ratifiant son règlement N° 23, augmentant son capital autorisé de $199,000 à $400,000 par la création de 2010 actions ordinaires additionnelles de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 24 août 1951.L'Assistant-procureur général, 30903 L.DÉSILETS.Pruneau, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 23 août 1951 à la compagnie \"Pruneau, Limited\", ratifiant son règlement N° 17, augmentant son capital autorisé de $20,000 à $120,000 par la création de 20,000 actions privilégiées de 85 chacune, sujettes aux droits et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 23 août 1951.L'Assistant-procureur général, 30903 L.DÉSILETS.W.E.Baxter, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 21 août 1951 à la compagnie \"W.E.Baxter, Limited\", ratifiant son règlement 20: 1°) diminuant son capital-actions de $20,000 à $10,000 par l'annulation de 100 actions ordinaires non émises de $100 chacune: 2°) augmentant ledit capital-actions de $10,000 à $85,000 par la création de 7,500 actions privilégiées de $10 chacune, sujettes aux droits, restrictions et privilèges mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 21 août 1951.L'Assistant-procureur général, 30903 L.DÉSILETS.ters patent, bearing date August 24, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Alphonse Gratton Inc.\", ratifying its By-law No 6 increasing its authorized capital stock from $20,000 to $120,000, by the creation of 1,000 new preferred shares of $100 each, subject to the rights and restrictions set forth in the said By-law.Dated at the office of the Attorney General, August 24, 1951.L.DÉSILETS, 30903 Deputy Attorney General.Najeeb Lawand & Sons, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of August, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Najeeb Lawand & Sons, Limited\", ratifying its By-Law No.23 increasing its authorized capital from $199,000 to $400,000 by the creation of 2010 additional common shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this 24th day of August, 1951.L.DÉSILETS, 30903-o Deputy Attorney General.Pruneau, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 23rd day of August, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Pruneau, Limited\", ratifying its By-Law No.17 increasing its authorized capital stock from 820,000 to $120,000 by the creation of 20,000 preferred shares of $5 each, subject to the rights and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 23rd day of August, 1951.L.DÉSH.ETS, 30903-o Deputy Attorney General.W.E.Baxter, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st of August, 1951.were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"W.E.Baxter, Limited\", ratifying its By-Law 20: 1°) reducing its capital stock from $20,000 to $10,000 by the cancellation of 100 unissued common shares of $100 each; 2°) increasing such capital stock from $10,000 to $85,000 by the creation of 7500 preferred shares of $10 each, subject to the rights, restrictions and privileges mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 21st day of August, 1951.L.DÉSDLETS, 30903-o Deputy Attorney General. 2406 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 septembre 1951, Tome 83, N° 37 Lettres patentes annulées Letters Patent Annuled Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu Notice is hereby given that in virtue of Order de l'arrêté en conseil numéro 980, en date du in Council number 980, dated September 5, 5 septembre 1951, adopté sous l'autorité des 1951, adopted under the authority of the pro-dispositions de l'article 4 de la loi 10, George VI, visions of section 4 of the Act 10 George VI, chapitre 48, l'annulation des lettres patentes chapter 48, the annulment of the letters patent des compagnies ci-après mentionnées a été of the companies hereinafter mentioned has been décrétée, à savoir: enacted, to wit: Nom de la Compagnie: Constituée le: Siège social: Name of the company: Incorporated on: Head Office: L'Agence Provinciale d'Assurance et d'Accomo-dement Limitée \u2014 The Provincial Insurance and Adjustment Agency Limited.13 novembre 1933.Montréal.Alderson & Mackay, Incorporated.1er octobre 1930 .Montréal.Art Moderne Français Limitée.20 mars 1926.Mont real.L'Association des Transports du Sud Inc.\u2014 Southern Transport Association Inc.7 juillet 1932 .Trois-Rivières.Les Ateliers Paul et Jean & Cie Limitée.29 juillet 1937 .Ste-Croix, cté Lotbinière.P.E.Bégin Limitée.20 avril 1937 .Lévis.Boiler Inspectors' Association of the Province of Quebec, Inc.18 février 1933.Montréal.La Bourse du Travail, Ltée.18 février 1921.Montréal.William Cairns, Limited.16 septembre 1916 .Montréal.The Catholic Girls Association, Inc.5 mars 1932.Montréal.Chait Construction Company.31 mai 1927.Outremont, P.Q.Le Clairon Inc.16 janvier 1936 .Montréal.Le Club Versailles Incorporé.7 mai 1936.Montréal.Commercial & Tourists Travel Bureau Ltd.5 avril 1946 .Montréal.La Cie de Construction Calabrese Limitée.9 septembre 1936 .Montréal.La Compagnie de Construction du Nord de la Gatineau Ltée.2 février 1937.Maniwaki.The Continental Drug and Chemical Company .23 avril 1907 .Montréal.Continental Soya Company Limited.24 juillet 1937 .Montréal.Cosmo Ornament Company Limited.:.7 février 1935.Montréal.Cote St-Luc Realty & Investment Company, Limited.4 mai 1931.Montréal.Cowansville Hardware Limited \u2014 Ferronnerie Cowansville (Limitée).12 juillet 1939 .Cowansville, P.Q.Crédit Central Incorporé \u2014 Central Credit Incorporated.2 juillet 1936 .Montréal.La Compagnie de Crédit de Construction Canadienne Limitée \u2014 Canadian Construction * ^ Credit Company Limited.25 avril 1939 .Montréal.('redit & Investigation Service Corporation Ltd.12 juin 1940.Montréal.Dominion Skis Limited.25 avril 1938 .Québec.Upper Roslyn Realty Corporation.24 novembre 1936.Montréal.Le Procureur général The Attorney general de la province de québec, of the province of ouebec, par L.DESILETS, per L.DÉSILETS, 30899-o .Assistant-procureur général.30899-c Deputy Attorney General.Actions en séparation de biens AVIS LÉGAL Canada, Province de Québec, District de Terrebonne, Cour Supérieure, N° 10,670.Dame Irène Duquette, demanderesse; vs Lionel Beau-champ, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause, le 25e jour d'août 1949.Le Procureur de la demanderesse, 30883-o - LUCIEN THINEL.Actions for separation as to property LEGAL NOTICE Canada, Province of Quebec, District of Terrebonne, Superior Court, No.10,670.Dame Irène Duquette, plaintiff; vs Lionel Beauchamp, defendant.An action for separation as to proprety was instituted in this case, on the 25th day of August, 1949.LUCIEN THINEL, 30883 Attorney for the plaintiff. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 15th, 1951, Vol.83, No.87 2497 Dame Corinne Bourque, épouse de Isaac Boudreau, marchand, domicilié à Havre-aux-Maisons, Iles de la Madeleine, a formé contre son mari une demande en séparation de biens.Cap-au-Meules, le 5 septembre 1951.L'Avocat de la demanderesse, 30881-o HONORÉ DIONNE.Dame Marie Léger, épouse de Ephrem Desjar-dins, marchand, domicilié à Havre-aux-Maisons, lies de la Madeleine, a formé contre son mari une demande en séparation de biens.Cap-aux-Meules, le 5 septembre 1951.y .L'Avocat de la demanderesse, 30882-o HONORÉ DIONNE.Action en séparation de corps et de biens Canada, Province de Québec, District de Nicolet, Cour Supérieure, N° 1758.Dame Léo-nie Roux, domiciliée et résidant au village de Manseau, district de Nicolet, épouse commune en biens de Emery Spénard.journalier, domilié aux mêmes lieux, mais actuellement résidant en la cité de Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, demanderesse; vs ledit Emery Spénard, journalier, domicilié au village Manseau, district de Nicolet, et actuellement résidant en la cité de Trois-Rivières, district de Trois-Rivières.défendeur.Une action en séparation de corps et de biens a été instituée en cette cause le C septembre 1951.Le Procureur de la demanderesse, ANDRÉ VIGEANT.Avis divers J.-B.Laliberté Inc.Règlement \"B\" \"Résolu que le règlement suivant soit et il est par les présentes adopté comme Règlement \"B\" de la compagnie, savoir: 1° Que le nombre de directeurs composant le bureau de direction soit et il est réduit par les présentes de sept à cinq directeurs.2° Que les règlements de la compagnie soient et ils sont par les présentes amendés pour donner pleine et entier effet à cette réduction dans le nombre des directeurs.\" Certifié vraie copie à Québec, ce 4ième jour de mai 1951.Le Secrétaire, 30885-o GÉRARD PLANTE.Kimball Automobile Ltêe \"Règlement N° 18 \u2014 Lequel constitutait au préalable un bureau de direction de (3) trois directeurs, a été modifié pour se lire comme suit: \"Règlement N° 18 \u2014 Le bureau de direction sera composé de (4) quatre actionnaires qui auront charge de l'administration des affaires de la compagnie, comprenant les pouvoirs usuels attribués aux directeurs.\" Certifié vraie copie.Le Secrétaire-trésorier, 30886 J-P.PEPIN.Dame Corinne Bourque, wife of Isaac Boudreau, merchant, domiciled at Havre-aux-Maisons, Magdalen Islands, has taken an action against her husband for separation as to property.Cap-aux-Meules, September 5, 1951.HONORÉ DIONNE, 30881 Attorney for the Petitioner.Dame Marie Léger, wife of Ephrem Desjar-dins, merchand, domiciled at Havre-aux-Maisons» Magdalen Islands, has taken an action against her husband for separation as to property.Cap-aux-Meules, September 5, 1951.HONORÉ DIONNE, 30882 Attorney for the Petitioner.Action for Separation as to Bed and Board and Property Canada, Province of Quebec, District of Nicolet, Superior Court, No.1758.Léonie Roux, domiciled and residing in the village of Manseau, district of Nicolet, wife common as to property of Emery Spénard, laborer, domiciled in the same place, but actually residing in the City of Trois-Rivières, district of Trois-Rivières, plaintiff; vs said Emery Spénard, laborer, domiciled in the village of Manseau, district of Nicolet and actually residing in the city of Trois-Rivières, district of Trois-Rivières, defendant.An action for separation from bed and board has been instituted in this case on the 6th of September 1951.ANDRÉ VIGEANT, 30884-o Attorney for the plaintiff.Miscellaneous Notices J.-B.Laliberté Inc.By-law \"B\" Resolved that the following By-law be and it is hereby adopted as By-law \"B\" of the company, to wit: 1.That the number of directors forming the Board of Directors be and it is hereby reduced from seven to five directors.2.That the by-laws of the company be and the same are hereby amended to give full and entire effect to such reduction in the number of directors.\" Certifies true copy, Quebec this 4th day of May, 1951.GÉRARD PLANTE, 30885 Secretary.Kimball Automobile Ltée \"By-Law No.18 \u2014 which previously constituted* a Board of (3) three Directors was amended to read as follows: \"By-Law No.18 \u2014The Board of Directors will consist of (4) four shareholders which will have charge of the administration of the Company's business including the usual powers attributed to Directors.\" Certified a true copy.J.-P.PEPIN, 30886-o Secretary-Treasurer.\u2022 2498 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 septembre 1961, Tome 83, N° 37 AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la loi 11 George VI, chapitre 52, article 5, l'honorable Secrétaire de la province a décrété, le 31 août 1951, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"L'Association des Employés de Canadian General Electric Co.Ltd.(Montreal Works)\", dont la formation a été autorisée le 20 mai 1949, avec siège social à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 7 septembre 1951.Le Sous-secrétaire de la province, 30887-o JEAN BRUCHÉSI.L'Association Sportive d'Amos Inc.Règlemenl No 4 \"Attendu que la compagnie \"L'Association Sportive d'Amos Inc.\" a été incorporée en vertu de la Loi des compagnies de Québec, 1ère partie, par lettres patentes émises le 22 août 1947, avec un nombre de six directeurs; Attendu qu'il serait maintenant préférable que le nombre des directeurs soit augmenté à dix; Sur proposition de M.Lucippe Hivon, il est résolu à l'unanimité, par le présent règlement, portant le N° 4, que le nombre des directeurs de la compagnie soit augmenté à dix, et que le président et le secrétaire soient autorisés à faire les démarches et formalités requises en conséquence.\" \\ Fait et passé à Amos, ce deuxième jour de mai 1949.Copie certifiée.Le Président, LUCIPPE HIVON.Le Secrétaire, 30888-o ZENON BACON.Lanthier & Sons Limited Règlement spécial \"A\" Un règlement concernant la distribution de l'actif de \"Lanthier & Sons Limited.\" 10 Attendu que la compagnie a cessé d'exercer son commerce, sauf aux fins de ventilation de ses affaires; et 2° Attendu que la compagnie n'a pas de dettes ou obligations, En conséquence, qu'il soit décrété comme un règlement de la compagnie \"Lanthier & Sons Limited\" que: a) La compagnie soit et elle est par les^ présentes autorisée à disposer de ses biens, distribuer son actif au pro rata entre ses actionnaires et procéder subséquemment à sa dissolution par voie d'abandon de charte en vertu de l'article 26 de la Loi des compagnies de Québec; b) Les directeurs et officiers sont par les présentes autorisés et dirigés à faire, signer et exécuter toutes choses, actes et documents nécessaires ou convenables pour la bonne exécution du précédent.Décrété le 7 septembre 1951.Le Secrétaire-trésorier, 30891 EDGAR-J.LANTRTER.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given, pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162, as added by the Act 11 George VI, Chapter 52, section 5, the Honourable the Provincial Secretary, under date of August 31, 1951, has enacted the termination of the corporate existence of the professional syndi cate \"L'Association des Employés de Canadian General Electric Co.Ltd.(Montreal Works)\", the formation whereof was authorized on May 20, 1949, with head office at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, September 7, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30887 Under Secretary of the Province.L'Association Sportive d'Amos Inc.By-law No.4 \"Whereas the company \"L'Association Sportive d'Amos Inc.\" was incorporated under Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent issued on the twenty-second day of August 1947, with Directors being six in number; Whereas it would now be preferable that the number of directors be increased to ten; It was moved by Mr.Lucippe Hivon and, by the present by-law, bearing No.4, unanimously resolved, that the number of Directors of the company be increased to ten and that the president and the secretary be authorized to take the necessary steps and comply with the formalities required therefor.\" Done and passed at Amos, this second day of May, 1949.LUCIPPE HIVON, President.ZÉNON BACON, 30888 Secretary.Lanthier & Sons Limited Special By-law \"A\" Being a by-law respecting the distribution of the assets of \"Lanthier & Sons Limited\".1.Whereas the Company has ceased to carry on business except for the purpose of winding up its affairs; and 2.Whereas the Company has no debts or obligations Now, therefore, be it enacted as a By-law of \"Lanthier & Sons Limited\" that: a) The Company be and it is hereby authorized to dispose of its property, distribute its assets reteably amongst its shareholders and subsequently proceed to dissolution by way of surrender of Charter under Section 26 of the Quebec Companies' Act; b) The directors and officers are hereby authorized and directed to do, sign and execute all things, deeds and documents necessary or desirable for the due carrying out of the foregoing.Enacted this 7th day of September, 1951.EDGAR-J.LANTHIER, 30891-o Secretary-Treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 16th, 1961, Vol.88, No.37 2499 Spearton Investments Limited Règlement \"D\" passé par les directeurs de la compagnie \"Spearton Investments Limited\", le 6 août 1951.Attendu que la compagnie a cessé d'exercer son commerce, sauf aux fins de ventilation de ses affaires et n'a pas de dettes ou obligations: En conséquence, qu'il soit et il est par les présentes décrété: Que l'actif de la compganie soit distribué en espèces, au pro-rata entre les actionnaires de la compagnie, conformément à leur détention respective du capital-actions de la compagnie.Daté à Montréal, le 6 août 1951.Spearton Investments Limited, Le Secrétaire-trésorier, 30889 E.M.EDSON.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Syndicat Coopératif d'Aqueduc de St-Yvon\", en date du 21 juillet 1951, dont le siège social est situé à Saint-Y von, comté de Gaspé-Nord, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Doimé au bureau du Secrétaire de la Province, le 30 août 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 30890-e JEAN BRUCHÉSI.Union Investors Limited Sommaire du règlement spécial \"A\" intitulé \"Un règlement pourvoyant à la distribution de l'actif de la compagnie entre les actionnaires\", passé par les directeurs le 15 août 1951.Ledit règlement spécial \"A\" pourvoit à la distribution au pro rata entre les actionnaires de la compagnie de tout l'actif restant, une première distribution au taux de $13.95 par action sera faite pas moins que quinze jours suivant la publication du présent sommaire dans la Gazette officielle de Québec et une autre distribution ou distributions seront faites subséquemment à tel moment ou moments et pour tel montant ou montants que les directeurs pourront, subséquemment, déterminer par résolution.Je, le soussigné, secrétaire de la compagnie \"Union Investors Limited\", certifie, par les présentes, que le précédent est un sommaire exact du règlement spécial \"A\" de ladite compagnie passé par les directeurs lors d'une assemblée dûment convoquée et tenue en la cité de Montréal le 15 août 1951.En foi de quoi, j'ai signé ce lOième jour de septembre 1951.Le Secrétaire, 30901 C.C.PARKES.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Chantier Coopératif N.-D.de Lourdes\", en date du 11 août 1950, dont le siège social est situé à Notre-Dame de Lourdes, comté de Mégantic, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 28 août 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 30909-o JEAN BRUCHÉSI.Spearton Investments Limited By-law \"D\" passed by the Directors of \"Spearton Investments Limited\", on 6th August, 1951.^yhereas the Company has ceased to carry on business except for the purpose of winding up its affairs and has no debts or obligations: Now therefore be it and it is hereby enacted: That the assets of the Company shall be distributed in specie among the shareholders of the Company pro rata and according to their several holdings in the Capital Stock of the Company.Dated at Montreal, the 6th day of Augst, 1951.Spearton Investments Limited, E.M.EDSON, 30889-o Secretary-Treasurer.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Coopératif d'Aqueduc de St-Yvon\", under date the 21st day of July, 1951, whereof the head office is at Saint-Yvon, county of Gaspé-North and that the said document has been filed in the archives of the département of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this thirtieth day of August, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30890 Under Secretary of the Province.Unions Investors Limited ?\u2014 Summary of Special By-law \"A\", entitled \"A By-Law for distributing the assets of the Company among the Shareholders\" passed by the Directors on August 15, 1951.The said Special By-law \"A\" provides for the distribution pro rata amongst the Shareholders of the Company of all of its remaining assets, a first distribution at the rate of $13.95 cash per share to be made not less than fifteen days following the publication of the present summary in the Quebec Official Gazette and a further distribution or distributions to be made thereafter at such time or times and in such amount or amounts as the Directors may hereafter determine by resolution.I the undersigned, Secretary of \"Union Investors Limited\", do hereby certify that the foregoing is an accurate summary of Special By-law \"A\" of the said Company passed by the Directors at a meeting only called and held at the City of Montreal on August 15th, 1951.In witness whereof, I have signed this 10th day of September 1951.C.C.PARKES, 30901-o m Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Chan-tier Coopératif N.-D.de Lourdes\" under date the eleventh day of August, 1951, whereof the head office is at Notre-Dame de Lourdes.county of Megantic, and the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th of August, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30909 Under Secretary of the Province. 2500 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 septembre 1951, Tome 83, N° 37 AVIS DE CHANGEMENT DE NOM (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a autorisé, le dix septembre 1951, le changement de nom \"L'Association des Employés de Turner & Newall (Canada) Ltd.\" en celui de \"L'Association des Employés de \"Atlas Asbestos Company Limited\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941.chapitre 162.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 11 septembre 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 30910-o JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné par le maire et le secrétaire-trésorier de la municipalité de la paroisse de St-Louis-de-Gonzague-de-Pintendre, comté de Levis, que le Lieutenant-Gouverneur en conseil a approuvé en date du 29 août 1951, suivant un rapport du Comité de l'honorable Conseil exécutif, le changement de nom de la municipalité de la paroisse de St-Louis-de-Gon-zague-de-Pintcndre en celui de \"Municipalité de la paroisse de St-Louis de Pintendre\" comté de Lévis.Conformément aux dispositions de l'article 48 du Code municipal, ce changement de nom entre en vigueur à compter de la date de la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.t * St Louis de Pintendre, ce cinquième jour de septembre 1951.Le Maire, ALPHONSE COUTURE.Le Secrétaire-trésorier, 30911-e GÉRARD DUMONT.AVIS (Loi (les syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Syndicat des Travailleurs du Fibre de Québec\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 29 août 1951.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Québec, district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la Province, 30912-o JEAN BRUCHESI.AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné qu'à son assemblée régulière du 5 septembre 1951, le Conseil de la Ville de Roxboro a adopté une résolution décidant en principe de changer la date des élections et que dans un délai de 30 jours à compter de la dernière insertion du présent avis dans la Gazette officielle de Québec, la Ville de Roxboro s'adressera au Lieutenant-Gouverneur en Conseil pour fixer au premier jour juridique de juillet la date des élections municipales.Daté à Montréal, ce 6ième mour de septembre Le Secrétaire-trésorier, JEAN FILION.NOTICE OF CHANGE OF NAME \"\\ (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary, under date of September tenth, 1951, authorized the change of name \"L'Association des Employés de Turner & Newall (Canada) Ltd\", into that of \"L'Association des Employés de \"Atlas Asbestos Company Limited\" and such pursuant to the provisions of section 7 of the Professional Syndicates' Act.R.S.Q.1941, chapter 162.Given at the office of the Provincial Secretary, September 11 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30910 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given by.the Mayor and the Secretary-Treasurer of the Municipality of the parish of St-Louis-de-Gonzague-de-Printcndre, county of Levis that the Lieutenant-Governor in Council has approved, under date of August 29, 1951 following a report of the Committee of Honourable the Executive Council, the change of name of the municipality of the parish of St-Louis-de-Pintendre, into that of \"Municipality of the parish of St-Louis de Pintendre county of Levis.Pursuant to the provisions of article 48 of the Municipal Code, the said change shall come into force from and after the date of the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.\" St.Louis dc Pintendre this fifth day of September, 1951.ALPHONSE COUTURE, Mayor.GÉRARD DUMONT 30911 Secretary Treasurer.NOTICE (Profcssionnal Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Syndicat des Travailleurs du Fibre de Quebec\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members has been authorized by the Provincial Secretary on August 29, 1951.The principal place of business of the said professional syndicate is at Quebec, judicial district of Quebec.JEAN BRUCHÉSI, 30912 Under Secretary of the Province.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that, at its regular meeting, held on September 5.195J, the council of of the Town of Roxboro adopted a resolution laying down the principle that the date of elections be changed and that within a delay of 30 days from the last insertion of the present notice in the Quebec Official Gazette the Town of Roxboro will apply to the Lieutenant-Governor in Council to fix to the first juridicial day of July, the date of the Municipal elections.Dated at Montreal, this sixth dav of September, 1951.JEAN FILION, 30917-37-4 Secretary Treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 16th, 1961, Vol.83, No.37 2501 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire Desjardins de Villeneuve\", en date du\"30 juillet 1951, dont le siège social est situé à St-Thomas de Villeneuve, comté de Québec, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 16 août 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 30918-o JEAN BRUCHÉSI.Association Recreative Alcan Extrait des règlements de l'association ci-haut mentionnée, tels qu'adoptés à l'assemblée tenue le 14 mai 1951, concernant l'augmentation du nombre de ses directeurs de trois à sept: \"Article IV \u2014 Contrôle et administration \u2014 Sec.1 \u2014 L'administration de l'Association et de ses propriétés sera assignée à un bureau de Direction composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier comme exécutif et de trois autres directeurs connus comme officiers de liaison et tous élus à leur poste par l'assemblée générale.\u2022 Le Secrétaire, 30924-o J.AUMOND.Fenimore Iron Mines limited Libre de responsabilité personnelle) Règlement No.72 (Concernant une augmentation du nombre des directeurs de la compagnie ci-dessus mentionnée, de cinq à sqpt) Qu'il soit dévrété comme règlement de la compagnie \"Fenimore Iron Mines Limited\" ce qui suit: Que le premier paragraphe du règlement *N° 3, étant partie des règlements généraux de la compagnie, tel que révoqué et de nouveau décrété comme le règlement N° 71, soit et il est par les présentes révoqué et le suivant est décrété pour le remplacer.Les affaires de la compagnie seront dirigées par un bureau de direction de sept (7) directeurs dont quatre (4) formeront quorum.Chaque directeur sera un actionnaire de la compagnie.Passé ce 30 avril 1951.Je certifie par les présentes, que le règlement ci-dessus a été passé par les directeurs de la compagnie ci-dessus mentionnée à une assemblée dûment convoquée et tenue le 30 avril 1951, et » que ce règlement a été dûment ratifié, sanctionné et confirme à une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie dûment convoquée et tenue à cette fin le premier juin 1951, par un vote unanime de sactionnaires présents ou représentés par procureation.(Sceau) Le Secrétaiee, 30927 J.D.McCORMACK.Gaspê Oil Ventures Limited Libre de responsabilité personnelle) Règlement \"X\" Que le règlement général N° 20 de la compagnie soit, et il est par les présentes amendé, pour augmenter le nombre des directeurs de cinq (5) à sept (7) de manière à ce que le règlement se lise comme suit: Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire Desjardins de Villeneuve\" under date the 30th day of July, 1951, whereof the head office is at St-Thomas de Villeneuve, County of Quebec, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this sixteenth day of August, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30918 Under Secretary of the Province.Association Recreative Alcan Excerpt from the By-laws of the above mentioned association, as adopted at the meeting held on May 14, 1951, concerning the increased in the number of its directors from three to seven.\"Article IV \u2014 Control and administration \u2014 Sec.1.The administration of the association and of its properties are assigned to a Board of Directors composed of a President, a Vice-President, a Secretary and a Treasurer, as executives, and of three other Directors as \"liaison\" officers, and all of whom to be elected to their positions by the general meeting.J.AUMOND, 30924 Secretary.Fenimore Iron Mines Limited (No Personal Liability) .By-Law 72 Concerning an increase in the directorate of the above named company from five to seven).Be it enacted as a By-law of \"Fenimore Iron Mines Limited\" as follows: That the first paragraph of By-law Number 3, being part of the General By-laws of the Company as repealed and re-encate'd as By-law Number 71, be and the same is hereby repealed and the following enacted in its place and stead: The affairs of this Company shall be managed be a Board of seven (7) Directors of whom four (4) shall form a quorum.Every Director shall be a shareholder of the Company.Passed this 30th day of April, 1951.\u2022 I hereby certify that the above By-law was passed by the Directors of the above company at a meeting duly called and held on the 30th day of April, 1951 and that the said By-law was duly ratified, sanctioned and confirmed at a Special General Meeting of the Shareholders of the company called and held for the purpose on the 1st day of June, 1951 by a unanumous vote of the Shareholders present thereat or represented by proxy.(Seal) .J: D.McCORMACK, 30927-o Secretary.Gaspé Oil Ventures Limited (No Personal Liability) By-Law \"X\" That General By-Law No.20 of the Company be and the same is hereby amended to increase the number of Directors from five (5) to seven (7) so that the By-Law shall now read: F 2502 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 septembre 1951, Tome 83, N° 87 \"A moins qu'il soit autrement déterminé, le nombre des directeurs sera sept (7) dont cinq (5) formeront quorum\".Copie certifiée du règlement \"X\" décrété par les directeurs, le 13 avril 1951, et ratifié à l'unanimité à une assemblée générale spéciale des actionnaires, tenue le 31 août 1951.La Secrétaire, 30928 LUCIENNE DEMERS.\"Unless otherwise determined the number of Directors shall be seven (7) of whom Five (5) shall form a quorum.\" Certified cofty of By-Law \"X\" enacted by the Directors on the 13th day of April 1951, and ratified unanimously at a Special General Meeting of Shareholders held August 31st, 1951.LUCIENNE DEMERS, 30928-o Secretary.Lumikay Manufacturing Inc.Règlement N° 2d Attendu qu'il est urgent d'augmenter le nombre des directeurs de la compagnie de trois à quatre.Qu'il soit par conséquent décrété comme règlement de la compagnie; Que le nombre des directeurs de la compagnie soit changé en augmentant le nombre des dits directeurs de trois à quatre, trois desquels formeront quorum.Et que le règlement N° 8 soit amendé en conséquence.Daté ce vingt-sept juin mil neuf cent cinquante et un.Le Président, B.WAINBERG.Le Secrétaire, 30934 IRVING M.SOLOWEY.Lumiray Manufacturing Inc.By-Law No.20 Whereas it is expedient to increase the number of directors of the company from three to four; Now therefore be it enacted as a By-law \"of the Company; That the number of directors of the Company be varied by increasing the number of such direc-.tors from three to four, three of whom shall form a quorum.And that by-law No.8 be amend to accord herewith.Dated this twenty-seventh day of June, one thousand nine hundred and fifty-one.President, B.WAINBERG.Secretary, 30934-o IRVING M.SOLOWEY.Bills, Assemblée législative Avis de l'Assemblée législative Concernant les bills privés qui seront présentés pendant la prochaine session.Aux termes du règlement, les bills privés devront être déposés avant le 17 octobre 1951 et présentés avant le 28 novembre 1951, les pétitions introductives de bills privés devront être présentées avant le 17 novembre 1951, et reçues avant le 22 novembre 1951, et les rapports de comités élus chargés de l'examen des bills privés devront être reçus avant le 12 décembre 1051.Québec, le 16 août 1951.Le Greffier, 30719-33-12-0 ANTOINE LEMD3UX.Chartes \u2014 Abandon de Bills, Legislative Assembly Notice of the Legislative Assembly Relating to private bills to be introduced during the coming session.Under the rules and standing orders, private bills must be deposited before the' 17th October, 1951 and introduced before the 28th November, 1951, petitions for the introduction of private bills must be presented before the 17th November, 1951, and received before the 22nd November, 1951, and the reports from select committees charged with the examining of private bills must be received before the 12th December, 1951.Quebec, August 16, 1951.ANTOINE LEMD3UX, 30719-33-12-o Clerk.Charters \u2014 Surrender of Avis d'abandon de charte Notice of Surrender of Charter \"La Corporation d'Aqueduc C.F.L.P.R.,\" ineporée suivant la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, le 18 mai 1935, donne avis qu'elle demandera à l'Honorable Procureur Général de la Province, l'autorisation d'abandonner sa charte et la fixation d'une date pour la cessation des affaires de la compagnie.Montréal, le 7 juillet 1951.La Corporation d'Aqueduc C.F.L.P.R., Le Secrétaire, 30893-o LEOPOLD DAIGNEAULT.Notice is hereby given that \"La Corporation d'Aqueduc C.F.L.P.R.\", incorporated under part I of the Quebec Companies Act on May 18, 1935, will apply to the Honourable Genera^ Attorney of the Province of Quebec to be authorized to surrender its charter and will ask that a date be set for the cessation of the affairs of the Company.Montreal, July 7, 1951.La Corporation d'Aqueduc C.F.L.P.R., LEOPOLD DAIGNEAULT, 30893-o Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 15th, 1051, Vol.83, No.37 2503 Lanthier & Sons Limited Avis est par les présentes donné que la compagnie \"Lanthier & Sons Limited\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, s'adressera au Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, pour lui demander la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 7 septembre 1951.Lanthier-& Sons Limited, Le Secrétaire-trésorier, 30892 ' E.-J.LANTHIER.Lanthier $; Sons Limited Notice is hereby given that \"Lanthier & Sons Limited\", incorporated under the Quebec Companies' Act, intends to apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its Charter.Montreal, September 7.1951.Lanthier & Sons Limited, E.-J.LANTHIER, 30S92-o Secretary-Treasurer.AVIS LEGAL Avis est donné que la compagnie \"Natalie Inc.\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d-abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, le 20 août 1951.Le Secrétaire, E.J.DROUIN.Les Procureurs de la compagnie, Fitch & Levitsky, avocats, 132 ouest, rue St-Jacqucs, Montréal.30913 LEGAL NOTICE Notice is hereby given that \"Natalie Inc.\", a corporation constitued under the Quebec Companies Act, and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies Act.Dated at Montreal, this 20th day of August, 1951.E.J.DROUIN, Secretary.Fitch & Levistky, avocates, 132 St, James St.W., Montreal, Attorneys for Company.30913-o Demandes à la Législature AVIS Avis est par les présentes donné, que les RR.SS.Hospitalières de l'Hôtel-Dieu St-Michel de Roberval, présenteront à la prochaine Législature de Québec, une pétition introductive d'un bill privé par laquelle elles demanderont à la Législature de Québec de passer un bill ou loi, constituant en corporation distincte et autonome, l'\"Hôtel-Dieu d'Alma\", avec, siège social dans la ville de StaJoseph d'Alma, et tous les droits, privilèges inhérents, nécessaires ou utiles à une telle corporation et Hôpital.Roberval, ce 16 août 1951.Le Procureur des requérantes, 30764-34-4-o W.H.GIRARD.Avis est donné que la Communauté des Religieuses de l'Hôpital Général de Québec, corporation constituée civilement par lettres patentes du roi de France en date de mars 1692, complétées par la loi 12 Victoria, chapitre 140, s'adressera à la Législature de Québec, à sa prochaine session, pour obtenir des amendements à ladite loi aux fins suivantes: mieux définir ses buts et certains pouvoirs qu'elle a actuellement; acquérir toutes propriétés mobilières et immobilières, pourvu que le revenu annuel des immeubles appartenant à la corporation et possédés par elle pour fins de revenus n'excède pas la somme de cinq cent mille dollars; engager ses biens meubles et immeubles de toutes manières, pour assurer le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations, contractés spécialement par émission d'obligations ou d'autres titres ou valeurs; définir que les pouvoirs de la corporatoin seront exercés par son conseil, composé ainsi qu'il sera statué;.édicter des dispositions relatives à la dissolution de la corporation, à la représentation de ses membres Applications to Legislature NOTICE Notice is hereby given that \"Les RR.SS.Hospitalières de l'Hôtel-Dieu St-Michel de Roberval\" will apply to the Legislature of Quebec, at its next session, by a petition introducing a private bill whereby they will request from the Legislature of Quebec the passing of a Bill or Act, incorporating into a distinct and autonomous corporation \"Hôtel-Dieu d'Alma\", with head office in the town of St-Joseph d'Alma, with all the rights, privileges, attaching to, or necessary or useful for such a corpoiation and hospital.Roberval, August 16, 1951.W.H.GHIARD, 30764-34-4 Attorney for the Petitioners.Notice is given that the Community of the Sisters of the General Hospital of Quebec, a body civilly incorporated under Letters Patent of the King of France, dated of March 1692, and completed by the Act 12 Victoria, chapter 140, will apply to the Legislature of Quebec, at its next session, in order to obtain amendments to said Act, as follows: define more clearly its aims and certain powers that it now possesses; acquire all moveable and immoveable property, provided that the annual revenue of the immoveables belonging to the corporation and owned by it for purposes of revenue does not exceed five hundred thousand dollars; encumber its moveable and immoveable property in any way whatsoever, to secure the payment of its loans or the carrying of its obligations, specially by issuing bonds or other title-deeds or securities; declare that the powers of said corporation shall be exercised by its council, composed in the manner which shall be defined; enact dispositions relating to the dissolution of said corporation, to the représenta- 2504 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Quebec, 15 .septembre 1951, Tome 83, N° 87 par ladite corporation, aux officiers dont la signature liera celle-ci, à la modification de son nom corporatif et du siège social de celle-ci.Québec, 30 août 1951.Les Procureurs de la Communauté des Religieuses de l'Hôpital Général de Québec, 30850-30-4-o GUÉRARD ET PELLAND.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné, que les exécuteurs testamentaires des dernières volontés de feu Arthur Yale, à savoir: Dame Claire Yalc, des cité et district de Montréal, et Me Marc Vcr-mette, N.P., du village de Saint-Janvier, comté de Terrebonne, s'adresseront à la législature de Québec, par bill privé, à sa prochaine session, pour obtenir la modification de certaines clauses du testament de feu Arthur Yale, et l'autorisation de vendre le résidu des biens immobiliers faisant partie de la succession.Montréal, le 24 août 1951.Les Procureurs des requérants, Camiraxd, Dufort & Bergeron.30810-35-4-o AVIS Avis est par les présentes donné que Dame Immaculata Laferrièrc, de la cité de Montréal, veuve de Eugène Farley, de son vivant du même lieu, s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à sa prochaine session, pour l'adoption d'une loi aux fins d'obtenir l'autorisation de vendre certaines propriétés immobilières délaissées par M.Eugène Farly et faire le partage du produit de cette vente aux enfants issus du mariage.Montréal, le 28 août 1951.Le Procureur de la pétitionnaire, 30832-35-4-o PHILIPPE DANDURAND.Les Commissaires d'Ecoles POUR LA MUNICIPALITÉ de St-GeRMAIN de RlMOUSKI, DANS le COMTÉ de RlMOUSKI AVIS DE PÉTITION Avis est par lés présentes donné que les Commissaires d'Ecoles pour la municipalité scolaire de St-Germain de Rimouski, dans le comté de Rimouski, demanderont à la législature de la Province de Québec, à sa prochaine Session, d'adopter une loi aux fins d'imposer une taxe de vente de 1%, conformément à la loi dans les limites de son territoire.Rimouski, ce 28ième jour du mois d'août 1951.Les Procureurs des Pétitionnaires, 30831-35-4-o SIMARD & CHASSÉ, AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que Frederick Francis Myson, mouleur de la Ville de St-Laurent, près de Montreal, Que., s'adressera, par bill privé, à la législature de Québec à sa prochaine session, a fin de changer son nom de famille, ainsi que celle de ses enfants, de Myson à Griggs.Cowansville, Que., le 6 Septembre 1951.Le Procureur du Requérant, 30904-437-4-o W.F.BOWLES.C.R.tion by said corporation of its members, to the officers whose signatures shall bind said corporation, to the altering of its corporate name or the place of its corporate scat.Quebec, August 30th, 1951.GUÉRARD AND PELLAND, Attorneys for the Community of the Sisters of the General Hospital of 30S50-3G-4-o Quebec.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the testamentary Executors of the last will and testament of the late Arthur Yale, to wit: Dame Claire Yalc, of the city and district of Montreal, and Mr.Marc Vermette, N.P., of the village of St.Janvier, Terrebonne County, will apply to the Quebec Legislature, by private bill, at its next Session, to obtain the modification of certain clauses of the testament of the late Arthur Yale and the authorization to sell the residue of the immovables of the said Estate.Montreal, August 24, 1951.C AMIR AND, DurORT & BERGERON, Attorneys for Petitioners.30S10-35-4-o NOTICE Notice is hereby given that Dame Immaculata Laferrièrc, of the city of Montreal, widow of Eugène Farly, in his lifetime of the same place, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, for the passing of an Act for the purpose of securing authorization to sell certain immovable properties, left by M.Eugène Farley and to divide the product of such sale among the children born of the said marriage.Montreal, August 28,1951.PHILIPPE DANDURAND, 30832-35-4 Attorney for the Petitioner.The School Commissioners for the Municipality of St-Germain de Rimouski, in the County of Rimouski NOTICE OF PETITION Notice is hereby given that the School Com-missioneçs for the School Municipality of St-Gcrmain de Rimouski, in the county of Rimouski, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, for the passing of an Act for the purpose of levying a sale-tax of 1%, according to Law, within the limits of its territories.Rimouski, this twenty-eighth day of the month of August, 1951.SIMARD & CHASSÉ, 30831-35-4 Attorneys for the Petitioners.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that Frederick Francis Myson, moulder of the Town of St Laurent, near Montreal, Que., will apply ,by private bill, to the Legislature of Quebec, at its next session, to change his name and that of his children from Myson to Griggs.Cowansville, Que., September 6th, 1951.W.F.BOWLES.K.C.30904-37-4-o Attorney for Petitioner. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 15th, 1951, Vol.83, No.87 2505 Ville de Terreboxxe Avis est par les présentes donné par la Ville de Terrebonne, qu'elle s'adressera à la Législature provinciale, lors de sa prochaine session, pour obtenir des amendements à sa charte sur les matières suivantes: a) Pouvoir d'emprunt.b) Construire et exploiter des édifices publies.c) Autorisation à débourser les montants nécessaires pour publicité.d) Prohiber et réglementer les cirques ambulants.e) Changer les limites des quartiers électoraux./) Pouvoir de réglementer et taxer les boîtes téléphoniques.g) Prohiber les jeux de bagatelle et autres de même nature.h) Réglementer le stationnement, limiter le nombre des permis et imposer des taxes sur les autos-taxis.i) Changer les heures de votation pour les élections municipales.j) Payer une indemnité aux membres du conseil.k) Réglementer la construction.I) Contribuer aux déboursés de la commission industrielle.Montréal, le 7 septembre 1951.Le Procureur de la Ville de Terrebonne, 30905-37-4-o .FRS.FAUTEUX.AVIS PUBLIC Amendements à la Charte de la Cité Avis est par les présentes donné par la Cité de Verdun qu'elle s'adressera à la Législature provinciale, lors de sa prochaine session, pour obtenir des amendements à sa charte sur les matières suivantes: 1.Exploiter l'Auditorium Municipal; 2.Obtenir le droit d'emprunter pour exécuter certains travaux municipaux et pour la construction et l'aménagement d'un incinérateur; 3.Payer une pension annuelle au Recorder de la Cité; 4.Fixer l'indemnité des membres du Conseil de la Cité.Donné à l'Hôtel de Ville, Verdun, P.Q., ce Séjour de septembre 1951.Le Procureur de la Cité, 30919-37-4-o FRS.FAUTEUX, C.R.Town of Terreboxxe Notice is hereby given that the Town of Terrebonne will apply to the Provincial Legislature, at its next session, to obtain certain amendements on its charter on the following matters: a) Power to borrow.b) Build and operate public buildings.c) Authorization to disburse necessary amounts for publicity purposes.(/) Prohibit and regulate circus.e) Change electoral districts./) Regulate and impose telephone boots.g) Prohibit hazard games or \"bagatelles\" and other of similar nature.h) Regulate the parking, limit the number of permits and impose taxes on auto-taxis.i) Change hours of votation for municipal elections.-j) Pay an indemnity to the members of the council.Ic) Regulate the constructions./) Contribute to the disbursements of Industrial Commission.Montreal, September 7th, 1951.FRS.FAUTEUX, Attorney for the Town, of Terrebonne.30905-37-4-o - PUBLIC NOTICE Amendments to the City Charter Notice is hereby given by the City of Verdun that it will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at the next session, to obtain amendments to its charter on the following matters: 1.To operate the Municipal Auditorium; '2.To obtain the right to borrow for the construction of certain municipal works and to construct and equip and incinerator; 3.To pay an annual pension to the Recorder of the City; 4.To fix the indemnity of the members of the City Council.Given at the- City Hall, Verdum, P.Q., this 13th of September 1951.FRS.FAUTEUX, K.C.?30919-37-4-0 City Solicitor.Département de l'Instruction publique Department of Education N° 708-51.No.708-51.Québec, le 30 août 1951.Québec, August 30, 1951.Demande est faite de détacher de la munici- Application is made to detach from the school palité scolaire de Grondines, N° 1, paroisse, dans municipality of Gronines No.1, parish, in the le comté de Portncuf, les lots numéros 41 à 53 county of Portneuf, lots numbers 41 to 53 inclusi- inclusivement du cadastre officiel de la paroisse vely of the.official cadastre for the parish of St- de Sti-Charles-de-Grondines et de les annexer à la Charles-de-Grondines, and to annex the same municipalité scolaire de Grondines, N° 2, village, to the school municipality of Grondines No.2, dans le même comté.village, in the same county.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.J.DÉSAULNIERS, 30851-36-2-o O.J.DÉSAULNIERS, 30851-36-2 Superintendent of Education.N° 126-51.Québec, le 30 août 1951.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de la paroisse de Jonquière, dans le comté de Chicoutimi, les lots 26A, 26B et 27 et toutes les subdivisions du rang IV du Canton No.126-51.Québec, August 30, 1951.Application is made to detach from the school municipality of the parish of Jonquière, in the county of Chicoutimi, lots 26A, 26B and 27 and all the subdivisions of Range IV of the township 2500 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 septembre 1951, Tome 83, N° 37 de Jonquière et de les annexer à la municipalité scolaire de la ville de Jonquière, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 30852-30-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 895-51.Québec, le 8 septembre 1951.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire dissidente de Barnston, dans le comté de Stanstcad, les lots numéros 21-A et 21-B, du rang VII, du canton de Barnston et de les annexer, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaic de Ste-Suzanne-de-Bound-ary-Line, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 3090G-37-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 784-47.Québec, le 5 septembre 1951.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire du village de St-André de Sutton, dans le comté de Brome, les lots 500 et 509 à 522 inclusivement du cadastre officiel de la paroisse de Sutton, pour les annexer à la municipalité scolaire de Saint-Francois-d'Assisc-dc-Frelighsburg, dans le comté de Missisquoi.Le Surintendant de l'Instruction publique, 30907-37-2-o O.J.DESAULNIERS.Numéro 471-51.Québec, le 10 septembre 1951.Demande est faite de former en municipalité, scolaire distincte, sous le nom de \"Hauterivc\", dans le comté de Saguenay, le territoire ei-sessous décrit, qui n'est pas encore organisé au point de vue scolaire: Ce territoire comprendra la partie occidentale du canton Laflèchc, c'est à dire, un territoire borné au nord par la limite dususdit canton, à l'ouest et au sud par la rivière Manicouagan, à l'est par une ligne passant au centre de la rivière Araédée à partir du fleuve St-Laurent jusqu'au bloc \"K\" le bloc \"K\" sera entièrement compris dans la future municipalité scolaire; à partir du bloc \"K\" une ligne partant du coin nord-est du dit bloc, avec une orientation nord astronomique, jusqu'à la limite nord du canton Laflèchc; ce territoire comprendra aussi le bloc \"B\" du canton Eudes, les blocs \"D\" et \"M\" du canton Manicouagan ainsi que les lots 33B à 38B inclusivement du rang VI du même canton.Le Surintendant de l'Instruction publique, 30933-37-2-o O.J.DÉSAULNIERS, Département des Terres et Forêts of Jonquière, and to annex the same to the school municipality of the town of Jonquière, in the same county.O.J.DÉSAULNIERS, 30852-30-2 Superintendent of Education.No.895-51.Quebec, September 8, 1951.Application is made to detach from the dissentient school municipality of Barnston, in the county of Stanstead, lots.numbers 21-A and 21-B of range VII of the township of Barnston, and of Stc-Suzannc de Boundary-Line, in the same county.O.J.DESAULNIERS 3090G-37-2 Superintendent of Education.No.781-47.Quebec September 5, 1951.Application is made to detach from the school municipality of the village of St-André de Sutton, in the county of Brome, lots 506 and 5G9 to 522 inclusively, of the official cadastre for the parish of Sutton, to annex the same to the school municipality of Saint-François d'Assise de Frelighs-burg, in the county of Missisquoi.O.J.DESAULNIERS, 30907-37-2 Superintendent of Education.No.471-51.Quebec, September 10, 1951.Application is made to form into a separate school municipality under the name of \"Hauterivc\", in the county of Saguenay, the territory hereinunder described which is not yet organized from the viewpoint of schools: The territory will comprise the western part of the township Laflèchc, that is to say, a territory bounded on the north by the limit of the aforesaid township, out he west and south by the Manicouagan River, on the csat by a line passing in the centre of the Amédée River, starting from the St- Lawrence River as far as Block \"K\" the Block \"K\" will be entirely comprised in the future school municipality; starting from Block \"K\" a line starting from the northeast corner of said Block bearing north astronomically as far as the northen limit of the township Laflèche; this territory will also comprise Block \"B\" of the township Eudes, Blocks \"D\" and \"M\" of the township Manicouagan and also lots 33B to 38B inclusively of range VI of the same township.O.J.DÉSAULNIERS, 30933-37-2 Superintendent of Education.Department of Lands and Forests AVIS Cadastre officiel de la paroisse du Cap-de-la-Madeleine division d'enregistrement de Champlain Avis est par la présente donné que les lots 416-159 a 4i6-238 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 24 août 1951.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, AVILA BÉDARD, 30900-o Sous-ministre.NOTICE Officiai cadastre of the parish of Cap-de-la-Madelcine registration division of Champlain.Notice is hereby given that lots 416-159 to 416-238 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.» Quebec, August the 24th, 1951.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVIXA BÉDARD, 30900-o Deputy Minister. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September loth, 1951, Vol 83, No.87 2507 AVIS NOTICE Cadastre officiel du village de Mont-Laurier di- Official cadastre of the village of Mont-Laurier vision d'enregistrement de Labelle.registration division of Lahclle.Avis est par la présente donné (pie les lots 17 18, 19, partie du lot 15 Rang l sont annulés et le lot.1784 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 29 août 1951.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, A VILA BÉDARD, 30900-o Sous-Ministre.AVIS Notice is hereby given that lots 17, 18, 19, part of lot 15, Range I arc cancelled and lot 1784 is added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, August the 29th, 1951.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVI LA BÉDARD, 30900-o Deputy Minister.NOTICE Cadastre officiel du village de Pointe-Fortune Official Cadastre of the Village of Pointe-Fortune division d'enregistrement de Vaudrcuil.registration division of Yaudreuil.Avis est par la présente donné epic les lots 18-A-l et 18-A-2 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Quebec, le 29 août 1951.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, AVILA BÉDARD, 30900-o Sous-Ministre.Notice is hereby given that lots 18-A-l and 1S-A-2 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, August the 29th, 1951.Department of Lands and Forests, Cadastral Service, AVILA BÉDARD, 30900-o Deputy-Minister.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION Conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la Loi de la convention collective (Status refondus de Québec 1941, chapitre 103 et amendements), l'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes qu'il a l'intention de proposer l'approbation des modifications suivantes au décret numéro 3205 du 6 septembre 1940, dans sa teneur modifiée, relatif au commerce de détail dans la cité de Québec.Le paragraphe \"/\" de l'article II sera remplacé par le suivant: \"/) Chef de rayon: Le terme \"chef de rayon\" signifie et comprend tout employé (cf.paragraphe \"b\") qui a la charge de l'administration d'un rayon d'établissement commercial.Les chefs de rayon dont la rémunération hebdomadaire moyenne dépasse S75 ne tombent pas sous le coup de la présente définition et sont considérés comme faisant partie de la direction de l'entreprise.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 15 septembre 1951.'30930-0 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la conven- Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT Pursuant to the procedure set forth inscction 8 of the Collective Agreement Act (Revised Status of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Honourable Antonio Barrette, Minister of Lavour, hereby gives notice that he intends to recommend the approval of the following amendments to the decree number 3265 of Sep-temver 6.1940, as amended, relating to the retail trade in the city of Quebec.Subsection \"/\" of section II will be replaced by the following: \"/) Department head: The term \"department head\" means and includes any employees (cf.'subsection \"b\") who is in charge of the administration of a department in a commercial establis-nient.A department head whose average weekly remuneration exceeds $75.00 is not covered by the present definition and is considered as belonging to the management of the concern\".During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, September 15, 1951.30930-o - \u2022 NOTICE OF AMEND\\D3NT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant th the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agree- 2508 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 septembre 1951, Tome 83, N° 87 tion colllective de travail relative à l'industrie du fer et du bronze d'ornementation dans la region de Montréal, rendue obligatoire par le décret numéro 1250 du 16 novembre 1950, lui ont présenté une requête à l'effet d'amender ledit décret,dans sa teneur modifiée de la façon suivante: Les taux de salaires établie pour la zone I, à l'article II, seront remplacés par les suivants: Zone 1 Classifications: Taux Mécanicien.$1.38 Ajusteur .121 Forgeron.1.24 Aide (boutique ou chantier).1.11 Monteur.1-38 Il est entendu (pie les taux précédents seront réduits sur une basse de pourcentage pour chaque cinq points de baisse du coût de la vie.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec le 15 septembre 1951.30930-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette.Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux matériaux et aux travaux d'isolement en tuyauterie dans la région de Montréal, rendue obligatoire par la section \"B\" (article XXII-B) du décret néméro 579 du 7 juin 1951 relative à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal, lui ont présenté une requête à l'effet de modifier ladite convention de la façon suivante: 1° Les paragraphes \"/\" u Barreau: Bas St-Laurent: pratique du droit.2510 Hull: étude du droit.2511 Hull: pratique du droit.2511 Laurentides: pratique du droit.2511 Montréal: pratique du droit.2509 Montréal: pratique du droit.2510 Richelieu: étude du droit.2511 Richelieu: pratique du droit.2510 Richelieu: pratique du droit.2512 Greffes de notaires: Cyr, Lucien.2512 Lamoureux, Roland.2512 Provencher, Normand.2512 Lettres patentes: Alaska Quilting Corporation.2488 Arthur Guyot & Fils Limitée.2489 Associated Real Estate Appraisers Inc.2489 Crépeault & Fradette Limitée.2489 Employing Printers' Association of Montreal Inc.2489 Francois Bédard Inc.2490 Golden Valley Granite Co.Ltd.2490 Granby Lumber & Supply Ltd.2491 Green Valley Lodge Inc.2491 Greeting Cards Limited.2491 L'Association Catholique d'Etudes Bibliques au Canada.2492 L'Élégante Inc.2492 L'Institut des Oblates Bénédictines de Ville-Marie.2492 Nouvelle Pulpwood Limited.2493 Valleyfield Express Limitée \u2014 Valleyfield Express Limited.2493 Lettres patentes annulées: Diverses.2496 Lettres patentes supplémentaires: Alphonse Gratton Inc.2494 American Paper Box Co.Limited.2493 Compagnie d'Immeubles St.Pierre Limitée \u2014 St.Pierre Realties Company Limited.2494 Forster, McGuire & Company Limited 2494 Najeeb Lawand & Sons, Limited.2495 O.Chalifour, Incorporée.2494 Pruneau, Limited.2495 Regalco Limited.2494 W.E.Baxter, Limited.2495 Liquidations, avis de: Compagnie d'Aqueduc des Écureuils.2512 Corry & Leonard Electric Ltd.2513 Nominations: Diverses.2513 Proclamation: Convocation de la Législature pour l'expédition des affaires.2514 Ratification de titre: Bar Examinations: Lower St.Lawrence: practice of law .2510 Hull: study of law.2511 Hull: practice of law.2511 Laurentides: practice of law.2511 Montreal : practice of law.2509 Montreal: practice of law.2510 Richelieu: study of law.2511 Richelieu: practice of law.2510 Richelieu: practice of law.2512 » Notarial Records: Cyr, Lucien.2512 Lamoureux, Roland.2512 Provencher, Normand.2512 Letters Patent: Alaska Quilting Corporation.2488 Arthur Guyot & Fils Limitée.2489 Associated Real Estate Appraisers Inc.2489 Crépeault & Fradette Limitée .2489 Emploving Printers' Association of Montreal Inc.2489 François Bédard Inc.2490 Golden Valley Granite Co.Ltd.2490 Granby Lumber & Supply Ltd.2491 Green Valley Lodge Inc.2491 Greeting Cards Limited.2491 L'Association Catholique d'Etudes Bibliques au Canada.2492 L'Élégante Inc.2492 L'Institut des Oblates Bénédictines de Ville-Marie.2492 Nouvelle Pulpwood Limited.2493 Valleyfield Express Limitée \u2014 Valleyfield Express Limited.2493 Letters Patent Annulled: Miscellaneous.2496 Supplementary Letters Patent: Alphonse Gratton Inc.2494 American Paper Box Co.Limited.2493 Compagnie d'Immeubles St.Pierre Limitée \u2014 St.Pierre Realties Company Limited.2494 Forster, McGuire & Company Limited 2494 Najeeb Lawand & Sons, Limited.2495 O.Chalifour, Incorporée.2494 Pruneau, Limited.2495 Regalco Limited.2494 WE.Baxter, Limited.2495 Winding up Notices: Compagnie d'Aqueduc des Écureuils.2512 Corry & Leonard Electric Ltd.2513 Appointments: Miscellaneous.2513 Proclamation : Convocation of the Legislature for the dispatch of business.2514 Confirmation of Title: Langevin, Pon.ela & Marie-Louise.2515 Langevin, Pomela & Marie-Louise.2515 2528 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 septembre 1961, Tome 83, N° 37 Sièges sociaux: Head Offices: Associated Real Estate Appraisers Inc.2516 \u2022\u2022, Associated Real Estate Appraisers Inc.2516 Bart School Inc.2516 ' Bart School Inc.2516 Canapro Ltd.2516 Canapro Ltd.*.2516 J.-Adrien Boivin Limitée.2516 J.-Adricn Boivin Limitée.2516 Soumissions: Tenders: Ascot Corner, commission scolaire de.2518 Ascot Corner, School Commission of.2518 j£ Cowansville, ville de.2520 Cowansville, town of.2520 La Prairie, commission scolaire de la La Prairie, School Commission of the ville de____!.2516 town of.2516 Pointe-au-Pic, village de.2520 Pointe-au-Pic, village of.2520 Ste-Lucie de Doncaster, commission Ste-Lucie de Doncaster, School Commis- scolaire de.2519 sion of.2519 Ventes, Loi de faillite: Sales, Bankruptcy Act: Desrochers.Antonio.2521 Desrochers, Antonio.2521 Larose, Isaï.2522 Larose, Isai.2522 VENTES PAR SHÉRIFS: SHERIFFS' SALES: Arthabaska : Arthabaska : Bourque vs Héritiers Arthur Fauchon Bourque vs Heirs of Arthur Fauchon et al.2523 et al.2523 Desiochers vs Couture.2523 Desrochers vs Couture.2523 K amour aska: Kamouraska: Bérubé vs Caron.2523 Bérubé vs Caron.2523 Malenfant vs Cayouctte.2524 Malenfant vs Cayouctte.2524 Rimouski: Rimouski: Smith vs Lavoie.2524 Smith vs Lavoic.2524 Trois-Rivières : Trois-Ri vières : Durand vs Pépin.2525 Durand vs Pépin.2525 03935-o 30935-o Québec: \u2014Imprimé par Ré de m ft i Paradis, Quebec: \u2014Printed by Rédempti Paradis, imprimeur du Roi.King's Printer."]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.