Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 janvier 1955, samedi 22 (no 3)
[" Tomb 87, N° 3 183 Vol.87, No.3 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 22 janvier 1955 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, January 22nd, 1955 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter.3366 184 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion : 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 ligne» au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.38933 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies : 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once a'fe followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.38933 \u20141-52 Lettres patentes (P.G.12823-54) A.Couture Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf décembre 1954, constituant en corporation: Arthur Couture, maître-plombier, Zoti-que Couture, Guy Couture, comptables, Simone Bessette, ménagère, épouse séparée de biens de Joseph Bessette, et dûment autorisée par ce dernier, Pauline Letellier, ménagère, épouse séparée de biens de Jules Letellier, et dûment autorisée par ce dernier, tous de Sherbrooke, et Hollande Bessette, ménagère, épouse commune en biens de Léo Bessette, et dûment autorisée par ce dernier, de Bromptonville, tous du district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneur en plomberie, chaf-fage, ventilation et couverture, sous le nom de \"A.Couture Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Letters Patent (A.G.12823-54) A.Couture Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of December 1954, incorporating: Arthur Couture, master plumber, Zotique Couture, Guy Couture, accountants, Simone Bessette, housewife, separate as to property of Joseph Bessete, and duly authorized by the latter, Pauline Letellier, housewife, wife separate as to property of Jules Letellier, and duly authorized by the latter, all of Sherbrooke, and Rollande Bessette, housewife, wife common as to property of Léo Bessette, and duly authorized by the latter, of Bromptonville, all of the judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To act as a plumbing contractor, and that of heating, ventilation and roofing, under the name of \"A.Couture Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1965, Vol.87, No.S 185 Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 390G2-o C.E.CANTIN.(P.G.12921-54) Adélard Pelletier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux décembre 1954, constituant en corporation: Adélard Pelletier, industriel, Denis Fortin, comptable, et Bernadette Pelletier Fortin, épouse séparée de biens dudit Denis Fortin, tous de La Sarre, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneur général, sous le nom de \"Adélard Pelletier Inc.\", avec un capital total de 560,000, divisé en 600 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à La Sarre, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le deux décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12959-54) Alligator Leather Goods Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trentième jour de novembre 1954, constituant en corporation: Max S.Kaufman, avocat, de Westmount, Joseph Roy Hoffman, avocat, Oscar Respitz, étudiant, de Montréal et Léonore Gloven, secrétaire, fille majeure, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de marchandises en cuir, sous le nom de \"Alligator Leather Goods Co.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 2,000 actions privilégiées de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce trentième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.13062-54) Atlantic Pad Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du treize décembre 1954, constituant en corporation: Maynard B.Golt, avocat, Micheline Bertrand et Esther Monson, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, acheter et/ou vendre des bour-rures de tout genre et description, textiles et produits textiles, sous le nom de \"Atlantic Pad Co.Ltd.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions ordinaires .d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12921-54) Adélard Pelletier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of December, 1954, incorporating: Adélard Pelletier, industrialist, Denis Fortin, accountant, and Bernadette Pelletier Fortin, wife separate as to property of the said Denis Fortin, all of La Sarre, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To operate as a general contractor, under the name of \"Adélard Pelletier Inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 600 shares of $100 each.The head office of the company will be at La Sarre, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12959-54) Alligator Leather Goods Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of November, 1954, incorporating: Max S.Kaufman, advocate, of Westmount, Joseph Roy Hoffman advocate, Oscar Respitz, student, of Montreal, and Léonore Gloven, secretary, fille majeure, of Outrcmont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in leather goods, under the name of \"Alligator Leather Goods Co.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and into 2,000 preferred shares of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.13062-54) Atlantic Pad Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1954, incorporating: Maynard B.Golt, advocate, Micheline Bertrand and Esther Monson, secretaries, spinsters, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture, buy and/or sell pads of every manner and description and textiles and textile products, under the name of \"Atlantic Pad Co.Ltd.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 common shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 186 \" t GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 8 Daté du bureau du Procureur général, le treize décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.13014-54) Atlas Stone Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre décembre 1954, constituant en corporation: J.-Robert Boisvert, manufacturier, Jacques Laurence, André Aird, ingénieurs professionnels, Gaétan Brunet, garagiste, tous des cité et district judiciaire de Montréal, et L.Philippe Chapdelaine, manufacturier, de Sorel, district judiciaire de Richelieu, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de la pierre artificielle, de la pierre naturelle, de la brique, des minéraux, des matériaux de construction; exploiter des carrières; agir comme entrepreneur et constructeur, sous le nom de \"Atlas Stone Inc.\", avec un capital total de $95,000, divisé en 5,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 4,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre dtceir.bre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12894-54) Bellini Shoe Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuvième jour de novembre 1954, constituant en corporation: Louis Pascale, agent de voyage, Alfred Melrose West, avocat en conseil en Loi de la Reine, Jean Marier, Thérèse Dubé, et Joan Anderson, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de bottes et chaussures, marchandises en cuir et accessoires, sous le nom de \"Bellini Shoe Co.Limited\", avec un capital total de $50,000, divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune et 350 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-neuvième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.11864-54) Beth Jacob School Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois décembre 1954, constituant en corporation sans capital-actions: Henry Biberfeld, chimiste, Joseph Drazin, -teneur de livres, Tzudyk Mandelcorn, Solomon Amsel, fourreurs et Pin-kus Hirschprung, rabbin, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.13014-54) Atlas Stone Inc.Notice- is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of December, 1954, incorporating: J.-Robert Boisvert, manufacturer, Jacques Laurence, André Aird, professional engineers, Gaétan Brunet, garage-keeper, all of the city and judicial district of Montreal, and L.-Philippe Chapdelaine, manufacturer, of Sorel, judicial district of Richelieu, for the following purposes: To manufacture and deal in artificial stone, natural stone, brick, minerals, buildings materials; operate quarries; to carry on as a contractor and builder, under the name of \"Atlas Stone Inc.\", with a total capital stock of $95,000, divided into 5,500 common shares of $10 each and into 4,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12894-54) Bellini Shoe Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of November, 1954, incorporating: Louis Pascale, Travel Agent, Alfred Melrose West, advocate and Queen's counsel, Jean Marier, Thérèse Dubé and Joan Anderson, secretaries, spinsters, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and sell boots and shoes, leather goods and accessories, under the name of \"Bellini Shoe Co.Limited\", with a total stock of $50,000, divided into 150 common shares of $100 each and into 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.11864-54) Beth Jacob School Notice is hereby given that under the part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of December, 1954, to incorporate as a corporation without share capital: Henry Biberfeld, chemist, Joseph Drazin, bookkeeper, Tzudyk Mandelcorn, Solomon Amsel, furriers, and Pin-kus Hirschprung, rabbi, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 187 Établir et administrer, en la cité de Montréal, une école où les étudiants pourront recevoir une éducation religieuse et séculière, pourvoir à la donnée de lectures, classes et conférences ayant pour objet direct ou indirect l'avancement de la cause de l'éducation et diriger des services religieux conformes à la doctrine de la religion hébraïque, sous le nom de \"Beth Jacob School\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $75,000.\" Le siège social de la corporation sera à 417 ouest, Boulevard St-Joseph, app.3, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.12937-54) Bouchard & Clouticr Automobiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre décembre 1954, constituant en corporation: Conrad Cloutier, Marius Bouchard et Yvon Bouchard, tous commerçants, de Sept-Iles, district judiciaire de Saguenay, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de véhicules automobiles et exploiter des garages, sous le nom de \"Bouchard & Cloutier Automobiles Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 action ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sept-Iles, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le quatre décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12904-54) Breuvages Sherbrooke Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de là province de Québec des lettres patentes, en date du trente novembre 1954, constituant en corporation: Jules Lemieux, commerçant, Isabelle Normand-Lemieux, ménagère, épouse contrac-tuellement séparée de biens dudit Jules Lemieux, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes et Richard Bergeron, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Embouteiller, patenter, acheter, importer ou exporter toute liqueur gazeuse, non alcoolique, et généralement en exercer le commerce, sous le nom de \"Breuvages Sherbrooke Limitée\", avec un capital total de $25,000, divisé en 250 actions d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le treute novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.13064-54) Breuvages St.Jérôme Inc.To establish and carry on in the city of Montreal, a school where students may obtain a religious and secular education, to provide for the delivery of lectures, classes and conferences calculated directly or indirectly to advance the cause of education, and to conduct religious services in conformity with the Hebrew religion under the name of \"Beth Jacob School\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may possess, is to be limited, is $75,030.The head office of the corporation will be at 417 St.Joseph Blvd., west, Apt.3, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.12937-54) Bouchard & Cloutier Automobiles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of December 1954, incorporating: Conrad Clou-, tier, Marius Bouchard and Yvon Bouchard, all merchants, of Sept-Iles, judicial district of Saguenay, for the following purposes: To carry on the business of and deal in motor vehicles and operate garages, under the name of \"Bouchard & Cloutier Automobiles Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of a par value of $100 each and 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Sept-Iles, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of December 1954.C.E.CANTIN, 39062 ' Deputy Attorney General.(A.G.12904-54) Breuvages Sherbrooke Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of November 1954, incorporating: Jules Lemieux, merchant, Isabelle Normand-Lemieux, housewife, wife contractually separate as to property of the said Jules Lemieux, and duly authorized by him for the purposes herein, and Richard Bergeron, all of Sherbrooke, judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To bottle, license, buy, import or export, sparkling and non-alcholic drinks, and generally deal therewith, under the name of \"Breuvages Sherbrooke Limitée\", with a total capital stock of $25,000, divided into 250 shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13064-54) Breuvages St.Jérôme Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have 188 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1956, Tome 87, N° 3 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize décembre 1954, constituant en corporation: Eugène Lapointe, industriel, Angéline Pichette Lapointe, ménagère, épouse contractuel-lement séparée de biens dudit Eugène Lapointe et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous deux de Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne, et Lucienne Lapointe, fille majeure usant de ses droits, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'embou-teilleurs, d'eaux gazeuses, d'essences, de sirops, de liqueurs douces, de bouteilles, de bouchons, sous le nom de \"Breuvages St.Jérôme Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 250 actions communes de $100 chacune et en 750 actions privilériées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le treize décembre 1954.L'Assistant-procurcur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.13103-54) Cardinal Uranium & Copper Mines Inc.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf décembre 1954, constituant en corporation: Raphaël M.Phillips, administrateur, Shirley Greenfield, secrétaire, et Samuel J.Smiley, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Cardinal Uranium & Copper Mines Inc.\", (No Personal Liability), avec un capital total de $4,000,000, divisé en 4,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.13186-54) Castel des Prés Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1954, constituant en corporation: Roland Cossette, marchand d'appareils électriques, de Shawinigan-Sud, Paul-André Paradis, gérant, de la paroisse des Trois-Rivières, et Léo-J.Cossette, constructeur, du Cap-de-la-Madeleine, tous du district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Faire affaires comme hôteliers et restaurateurs, sous le nom de \"Castel des Prés Inc.\", avec un capital divisé en 3,000 actions sans valeur au pair ou nominale et en 2,000 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la paroisse des Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1954, incorporating: Eugène Lapointe, industrialist, Angéline Pichette Lapointe, housekeeper wife contractually separate as to property of the said Eugène Lapointe and duly authorized by the latter for these present purposes, both of Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne, and Lucienne Lapointe, spinster in use of her rights, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of and deal as bottlers, aerated waters, extracts, syrups, soft drinks, bottles, corks, under the name of \"Breuvages St-Jérôme Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 250 common shares of $100, each and into 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13103-54) Cardinal Uranium & Copper Mines Inc.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of December, 1954, incorporating: Raphaël M.Phillips, Executive, Shirley Greenfield, Secretary, and Samuel J.Smiley, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Cardinal Uranium & Copper Mines Inc.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $4,000,000, divided into 4,000,000 shares of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid >to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.13186-54) Castel des Prés Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1954, incorporating: Roland Cossette, merchant in electricla appliances, of Shawinigan-South, Paul-André Paradis, manager of the parish of Trois-Rivières, and Léo-J.Cossette, builder, of Cap-de-la-Madeleine, all of the judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on business as hotel and restaurant keepers, under the name of \"Castel des Prés Inc.\", with a capital stock divided into 3,000 shares without nominal and of no par value and into 2,000 preferred shares of $25 each.The head office of the company will be in the parish of Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.S 189 Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1954.L*Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.13184-54) Crépault Agencies Limited Agences Crépault Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour de décembre 1954, constituant en corporation : Raymond Crépault, comptable, Fleur-Ange (Florence) Allard Crépault, ménagère, épouse séparée de biensdudit Raymond Crépault, et Frédéric Edouard Farley, étudiant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de nouveautés, articles de toilette, marchandises de fantaisie, articles brevetés et objets divers négociés par les pharmaciens; caoutchouc, marchandises en caoutchouc et tous articles contenant du caoutchouc de quelque forme que ce soit, sous le nom de \"Crépault Agencies Limited \u2014 Agences Crépault Limitée\", avec un capital total de 825,000, divisé en 250 actions de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-deuxième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.12259-54) Disques Meteor Recordings Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier décembre 1954, constituant en corporation: Richard Crépeau, Guy Crépeau, avocats, Russell Marois et Pierre Légaré, marchands, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'enregistrement de disques et tout ce qui y est accessoire, sous le nom de \"Disques Meteor Recordings Incorporated\", avec un capital total de 320,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 125, rue Frontenac, Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12885-54) Dyno Flame (Que) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuvième jour de novembre 1954, constituant en corporation: Max S.Kaufman, avocat, de Westraount, Joseph Roy Hoffman, avocat et Oscar Rcspitz, étudiant, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Importer, exporter, manufacturer, distribuer, vendre, installer et faire le service d'accessoires de chauffage et de climatisation, sous le nom de \"Dyno Flame (Que) Inc.\", avec un capital total Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13184-54) ' Crépault Agencies Limited Agences Crépault Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issuee by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1954, incorporating: Raymond Crépault, accountant, Fleur-Ange (Florence) Allard Crépault, housewife, wife separate as to property of the said Raymond Crépault, and Frédéric Edouard Farley, student, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in novelties, toilet articles, fancy goods, proprietary articles and druggists' sundries; rubber, rubber goods and all articles containing rubber in any form, under the name of \"Crépault Agencies Limited \u2014 Agences Crépault Limitée\", with a total capital stock of S25.000, divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.12259-54) Disques Meteor Recordings Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December, 1954, incorporating: Richard Crépeau, Guy Crépeau, advocates, Russell Marois and Pierre Légaré, merchants, all of Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis, for the following purposes : To carry on the business of recording disks and in all pertaining thereto, under the name of \"Disques Meteor Recordings Incorporated\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at 125 Frontenac Street, Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12885-54) Dyno Flame (Que) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of November, 1954, incorporating: Max S.Kaufman, advocate, of Westmount, Joseph Roy Hoffman, advocate, and Oscar Respitz, student, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To import, export, manufacture, distribute, sell, install and service heating and air conditioning appliances, under the name of \"Dyno Flame (Que) Inc.\", with a total capital stock 190 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-neuvième jour de novembre 1954.*¦ L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.12913-54) Eastern Waste Paper & Bottle Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux décembre 1954, constituant en corporation: Madame Adjutor Brulotte, rentière, Thérèse B.O'Neill, ménagère, épouse contractuelle-ment séparée de biens de Roland O'Neill, et Roland O'Neill, gérant, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de regrattiers, sous le nom de \"Eastern Waste Paper & Bottle Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le deux décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.12913-54) Eastern Waste Paper & Bottle Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of December 1954, incorporating: Mrs Adjutor Brulotte, annuitant, Thérèse B.O'Neill, housewife, wife contractually separate as to property of Roland O'Neill, and Roland O'Neill, manager, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of hnuckters, under the name of \"Eastern Waste Paper & Bottle Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(P.G.11983-54) Emefem Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1954, constituant en corporation: Léon Tremblay, registrateur, Gisèle Gauthier, secrétaire, célibataire majeure, et Rodrigue Côté, notaire, tous de Matane, district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Faire le commerce d'entrepreneur général pour la construction, l'érection et la fabrication de tous genres de constructions publiques ou privées, sous le nom de 4 'Emefem Construction Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Matane, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(A.G.11983-54) Emefem Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1954, incorporating: Léon Tremblay, registrar, Gisèle Gauthier, secretary, spinster, and Rodrigue Côté, notary, all of Matane, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To carry on the business of a general contractor, for building, erection and the manufacturing of all kinds of public or private construction, under the name of \"Emefem Construction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Matane, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(P.G.13252-54) Fort Coulonge Mining Corporation (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuvième jour de décembre 1954, constituant en corporation: Jean Monette, avocat, de Longueuil, Richard Staines, comptable agréé, et Marguerite St-Pierre, téléphoniste, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Fort Coulonge Mining Corporation\" (No Personal Liability), avec un capital total de $5,000,000, divisé en 5,000,000 d'actions de $1 chacune.(A.G.13252-54) Fort Coulonge Mining Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1954, incorporating: Jean Monette, barrister, of Longueuil, Richard Staines, chartered accountant, and Marguerite St-Pierre, telephone operator, spinster, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Fort Coulonge Mining Corporation\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $5,000,-000, divided into 5,000,000 shares of $1 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 191 Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au-delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-neuvième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.12876-54) Frcdar Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux novembre 1954, constituant en corporation: Frederick Einil Kubinsky, administrateur, Charles Brownstein, avocat, et John Liberman, étudiant en droit, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Fredar Investment Corporation\", avec un capital total de $200,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $50 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.13004-54) Garage Grande-Vallée Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix décembre 1954, constituant en corporation: David Côté, garagiste, Émélie Fournier Côté, ménagère, épouse dudit David Côté, et Wilfrid Côté, mécanicien, tous de Grande-Vallée, district judiciaire de Gaspé, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagiste et exercer le commerce de véhicules automobiles, sous le nom de \"Garage Grande-Vallée Ltée\", avec un capital total de $75,000, divisé en 600 actions ordinaires de $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Grande-Vallée, district judiciaire de Gaspé.Daté du bureau du Procureur général, le dix décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12946-54) Garant Automobile Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de là province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six novembre 1954, constituant en corporation: Marcellin Thibault, chiropraticien, René Desharnais, commerçant, et André Claveau, courtier en assurances, tous des cité et district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'automobiles en général ; faire affaires comme garagiste et entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Garant Automobile The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.12876-54) Fredar Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of November, 1954, incorporating: Frederick Emil Kubinsky, Executive, Charles Brownstein, advocate, and John Liberman, student at law, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Fredar Investment Corporation\", with a total capital stock of $200,000, divided into 1,000 common shares of the par value of 850 each and into 3,000 preferred shares of the par value of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of November, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.13004-54) Garage Grande-Vallée Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of December, 1954, incorporating: David Côté, garage-keeper, Émélie Fournier Côté, housewife, wife of the said David Côté, and Wilfrid Côté, mechanic, all of Grande-Vallée, judicial district of Gaspé, for the following purposes: To carry on as garage-keeper, and to deal in motor vehicles under the name of \"Garage Grande-Vallée Ltée\", with a total capital stock of 875,000, divided into 600 common shares of $100 each and into 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Grande-Vallée, judicial district of Gaspé.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12946-54) Garant Automobile Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of November 1954, incorporating: Marcellin Thibault, chiropractor, René Desharnais, merchant, and André Claveau, insurance broker, all of the city and judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on the automobile business generally; act as garage-keepers and general contractors, under the name of \"Garant Automobile Ltée\"» 192 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 Ltée\", avec un capital total de 8170,000, divisé en S50 actions communes de 8100 chacune et en 850 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chicou-timi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.13051-54) Gary Lee Children's Wear Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du treizième jour de décembre 1954, constituant en corporation: Allan Marcus, avocat, David Kirshnblatt, étudiant, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal et Carol Burnley Jones, secrétaire, de St-Ilémi, district judiciaire d'Iberville, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements pour enfants, sous le nom de \"Gary Lee Children's Wear Limited\", avec un capital total de 820,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et 1,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce treisième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.12883-54) Gérard Potvin Construction Ltée Avis est donné qu'en .vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1954, constituant en corporation: Roland-Gérard Lefrançois, Jean Goulet, avocats, et Paulette Panneton, secrétaire, épouse majeure séparée de biens de Paul Panneton, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneur général, constructeur et couvreur, sous le nom de \"Gérard Potvin Construction Ltée\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12908-54) G.Potvin & Frères, Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1954, constituant en corporation: Gérard Potvin, épicier, Hilaire Potvin, bou-chefl et Maurice Lamontagne, notaire, tous de Saint-Félicien, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'épicier, sous le nom de \"G.Potvin & Frères, Ltée\", avec un capital de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Félicien, district judiciaire de Roberval.with a total capital stock of $170,000, divided into 850 common shares of $100 each and 850 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of November 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13051-54) Gary Lee Children's Wear Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1954, incorporating: Allan Marcus, lawyer, David Kirshnblatt, student, both of the city and judicial district of Montreal, and Carol Burnley Jones, secretary, of St.Rémi, judicial district of Iberville, for the following purposes: \u2022 To manufacture and deal in children's clothing, under the name of \"Gary Lee Children's Wear Limited\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.12883-54) Gérard Potvin Construction Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1954, incorporating: Roland-Gérard Lefrançois, Jean Goulet, advocates, and Paulette Panneton, secretary, wife of full age, separate as to property of Paul Panneton, and duly authorized by him for these present purposes, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractor, builder and roofer, under the name of \"Gérard Potvin Construction Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12908-54) G.Potvin & Frëres, Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by tne Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1954, incorporating: Gérard Potvin, grocer, Hilaire Potvin, butcher, and Maurice Lamontagne, notary, all of Saint-Félicien, judicial district of Roberval, for the following purposes : To operate as a grocer under the name of \"G.Potvin & Frères, Ltée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Félicien, judicial district of Roberval. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 193 Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12381-54) Grand'Mfcrc Foundry Ltd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le' Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize décembre 1954, constituant en corporation: Philippe Cantin, Laurier Matteau, industriels, Joseph-Eddy-Albé Matteau, homme d'affaires, Rémi Cantin et Marcel Cantin, mouleurs, tous de Grand'Mère, district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de fonderie, sous le nom de \"Grand'Mère Foundry Ltd\", avec un capital total de §90,000, divisé en 900 actions communes de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Grand'Mère, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le treize décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12381-54) Grand'Mère Foundry Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1954, incorporating: Philippe Can-tin, Laurier Matteau, industrialists, Joseph-Eddy-Albé Matteau business man, Rémi Cantin and Marcel Cantin, moulders, all of Grand'Mère, judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To operate a founding, and deal in smelting work under the name of \"Grand'Mère Foundry Ltd\", with a total capital stock of $90,000, divided into 900 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at Grand'Mère, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(P.G.13066-54) Guy Guénctte l^j6 (A.G.13066-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize décembre 1954, constituant en corporation: Guy Guénettc, vendeur, de Ville Saint-Laurent, Charles-J.Gélinas, C.R., avocat, d'Ou-tremont, et Pierre Bourque, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'accessoires et machineries employés dans l'industrie de la construction; exercer les opérations d'une compagnie foncière de construction et de développement, sous le nom de \"Guy Guénette Ltcf ' avec un caI)ital total de $25,000, divisé en 250 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à ' Ville Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.13011-54) Hôtel Chesnay Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept décembre 1954, constituant en corporation: Paul Dubé, hôtelier, Nohima Dumont Dubé, ménagère, épouse séparée de.biens dudit Paul Dubé, et Réal Dubé, contremaître, tous de Cabano, district judiciaire de Kamouraska, pour les objets suivants: Exploiter un ou des hôtels, auberges, maisons de rapport, maisons de chambres, maisons de pension, restaurants, sous le nom de \"Hôtel Chesnay Inc.\", avec un capital total de 850,000, divisé en 500 actions de $100 chacune.Guy Guénette j^je Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1954, incorporating: Guy Guénette, salesman, of the town of Saint-Laurent, Charles-.1.Gélinas, Q.C., advocate, of Outremount, and Pierre Bourque, .advocate of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in accessories and machinery employed in the building business, to carry on the operations of a real estate, build' ing and development company, under the nam\" Ltée\" .of \"Guy Guénette j^j ' with a total capita] stock of $25,000, divided into 250 shares of $100 each.The hçad office of the company will be at the town of Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13011-54) Hôtel Chesnay Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of December 1954, incorporating: Paul Dubé, hote-keeper, Nohima Dumont Dubé, housewife, wife separate as to property of the said Paul Dubé, and Réal Dubé, foreman, all of Cabano, judicial district of Kamouraska, for the following purposes: To operate one or more hotels, inns, apartment houses, rooming-houses, boarding-houses, restaurants, under the name of \"Hôtel Chesnay Inc.\", with a total capital stock of S50,000, divided into 500 shares of 8100 each, 194 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 8 Le siège social de la compagnie sera à Cabano, district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général, le sept décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12957-54) I.Kotler Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du premier jour de décembre 1954, constituant en corporation: Issie Kotler, Gordon Kotler, marchands, et Fanny Kadonoff Kotler, ménagère, épouse séparée de biens d'Issie Kotler et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de fruits de toute sorte, légumes et denrées alimentaires, sous le nom de 'T.Kotler Ltd.\", avec un capital total de $40,-000 divisé en 150 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce premier jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.12917-54) Immeubles Samson Realty Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois décembre 1954, constituant en corporation: Georges Samson, fils, agent d'immeubles, Bertha Bougie, opératrice de salle de quilles, épouse contractuel lement séparée de biens dudit Georges Samson, fils, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Guy Roy, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: - Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Immeubles Samson Realty Inc.\", avec un capital total de $35,000, divisé en 350 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.13074-54) Inter-America Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze décembre 1954, constituant en corporation: Elliot C.A.Crawford, administrateur, des cité et district judiciaire de Montréal, Stuart Wilcox Simmonds, administrateur, de Mansfield, Mass., U.S.A., Douglas Smerdon, avocat, de Taunton, Mass., U.S.A.et Paul E.Poirier, administrateur, des cité et district judiciaire de St-Hyacinthe, pour les objets suivants: Diriger et exercer le commerce comme constructeurs et entrepreneur généraux, sous le nom de \"Inter-America Development Corporation\", The head office of the company will be at Cabano, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of December 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12957-54) I.Kotler Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December, 1954, incorporating: Issie Kotler, Gordon Kotler, merchants, and Fanny Kadonoff Kotler, housewife, wife separate as to property of Issie Kotler and duly authorized by him for the purpose of these presents, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: The trade in all classes of fruit, vegetables and food stuffs, under the name of \"I.Kotler Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 150 common shares having a par value of $100 each and into 250 preferred shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.12917-54) Immeubles Samson Realty Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of December 1954, incorporating: Georges Samson, junior, real estate agent.Bertha Bougie, operator of a bowling alley, wife, contractually separate as to property of the said Georges Samson, junior, and duly authorized by for the purposes herein, and Guy Roy, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Immeubles Samson Realty- Inc.\", with a total capital stock of $35,000, divided into 350 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13074-54) Inter-America Development Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1954, incorporating: Elliot C.A.Crawford, business executive, of the city and judicial district of Montreal, Stuart Wilcox Simmonds, business executive, of Mansfiled, Mass, U.S.A., Douglas Smerdon lawyer, of Taunton, Mass, U.S.A., and Paul-E.Poirier, business executive, of the city and judicial district of St.Hyacinthe, for the following purposes: To conduct and carry on the business of builders and general contractors, under the name of \"Inter-America Development Corpo QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 195 avec un capital-actions composé de 4 actions ordinaires connues comme étant des actions catégorie \"D\", 5 actions privilégiées connues comme étant des actions catégories \"C\" et 2,000 actions privilégiées connues comme étant des actions catégories \"B\", toustes lesdites actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.13020-54) J.A.Bolduc Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six décembre 1954, constituant en corporation: Robert Gagnon, R.Padoue Tremblay, commerçants, et Jacqueline Savard, caissière, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer généralement le commerce de bijouterie, cadeaux, bibelots, argenterie, verrerie, porcelaine et vaisselle, sous le nom de \"J.A.Bolduc Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 362, rue St-Dominique, Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12950-54) J.Bastien & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf décembre 1954, constituant en corporation: Josaphat Bastien, entrepreneur, Jean Bastien, surintendant, René Bastien, contremaître, et Paul Bastien, comptable, tous de Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"J.Bastien & Fils Inc.\", avec un capital divisé en 300 actions sans valeur au pair ou nominale et en 450 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.\u2022 (P.G.12838-54) J.L.Lasnier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize décembre 1954, constituant en corporation: Jean-Marie Lasnier, industriel, d'Outremont, Gisèle Desroches, sténographe, célibataire majeure, et Jacques B.Viau, notaire, ces deux derniers de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: ration\", with a capital stock, consisting of 4 common shares to be known as class \"D\" shares, 5 preferred shares to be known as class \"C\" shares, and 2,000 preferred shares to be known as class \"B\" shares, all said shares having no nominal or par value.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.13020-54) J.A.Bolduc Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December 1954, incorporating: Robert Gagnon, R.Padoue Tremblay, merchants, and Jacqueline Savard, cashier, spinster, all of the city and judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To deal generally in jewellery, gifts, knick-kancks, silver-ware, glass-ware, porcelaine and chinaware, under the name of \"J.A.Bolduc Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 362 St.Dominique Street, Jonquière, judicial district of Chicoutimi.\u2022 Dated at the office of the Attorney General, this December sixth 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12950-54) J.Bastien & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of December 1954, incorporating: Josaphat Bastien, contractor, Jean Bastien, superintendent, René Bastien, foreman, and Paul Bastien, accountant, all of Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To carry on the business of general contractors and builders, under the name of \"J.Bastien & Fils Inc.\", with a capital stock divided into 300 shares without nominal or par value and 450 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of December 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12838-54) J.L.Lasnier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1954, incorporating: Jean-Marie Lasnier, industrialist, of Outremont, Gisèle Desroches, stenographer, bachelor of full age, and Jacques B.Viau, notary, the latter two of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: 196 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 Exercer l'industrie de manufacturiers de chandelles, bougies, cierges, lampions, articles ou objets enduits de cire, paraffine, stéarine ou toute autre substance de même nature, sous le nom de \"J.L.Lasnier Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 800 actions ordinaires d'une valeur au pair de $50 chacune et en 1,200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lon-gueuil, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.13091-54) J.Morcncy Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1954, constituant en corporation: Jean-Paul Pichette, négociant, Thérèse M.Pichette, ménagère, épouse séparée de biens dudit Jean-Paul Pichette, et Marcel Bélanger, comptable, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchandises composées en tout ou en partie, de cuir, caoutchouc, métal, métalloïde, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre, leurs produits et sous-produits, des merceries, produits comestibles, animaux, minéraux, pirrres précieuses, liqueurs douces, livres et périodiques, peintures, travaux d'art, produits chimiques, produits de la terre, de la mer et des forêts, produits de beauté, articles de toilette et parfums, sous le nom de \"J.Morency Inc.\", avec un capital total de $75,000, divisé en 500 actions communes de $100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12770-54) John Mâcher Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf décembre 1954, constituant en corporation: John Mâcher, John Penzcl, bouchers, et Regina Binder Mâcher, ménagère, épouse commune en biens de John Mâcher, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pourries objets suivants: Exercer le commerce de bouchers, marchands de viande, épiciers et marchands d'aliments, sous le nom de \"John Mâcher Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 3781 rue St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.To carry on a business as manufacturers of candles, small candles, tapers, small stout candles enclosed in small colored glass containers, articles or objects coated with wax, paraffin, stearin or other substance of the same kind, under the name of \"J.L.Lasnier Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 800 common shares of a par value of $50 each and into 1,200 preferred snares of a par value of $50 each.The head office of the company will be at Longueuil, judicial district of Montréal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13091-54) J.Morency Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1954, incorporating: Jean-Paul Pichette, dealer, Thérèse M.Pichette, housekeeper, wife separate as to property of the said Jean-Paid Pichette, and Marcel Bélanger, accountant, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes': To deal in merchandise composed wholly or in part of leather, rubber, metal, metalloid, wood, paper, nylon, plastic, furs, textiles, glass, their products and by-products, haberdashery, food products, animals, minerals, precious stones, soft drinks, books and periodicals, paintings, works of art, chemincal products, products of the soil, the sea and of the forests, beaty products, toilet articles and perfumes, under the name of \"J.Morcncy Inc.\", with a total capital stock of $75.000, divided into 500 common shares of $100 each and into 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12770-54) John Macher Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the LieutenantrGovernor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of December, 1954, incorporating: John Macher, John Penzel, butchers, and Rcgina Binder Macher, housekeeper, wife common as to property of John Macher, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of butchers, meat dealers, grocers, provision dealers, under the name of \"John Macher Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 3781, St.Lawrence St., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 197 (P.G.12933-54) Joseph C.Pardo Ltd.AyisTest donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deuxième jour de décembre 1954, constituant en corporation: Philip Fischel Vineberg, avocat, de Westmount, Arthur Franklin Gar-maise, avocat et Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de placements sur immeubles, sous le nom de \"Joseph C.Pardo Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce deuxième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.12856-54) Jos.Lavoie & Fils, Ltée.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois décembre 1954, constituant en corporation: Joseph Lavoie, Dollard Lavoie, Roch Lavoie, Yvon Lavoie, Raymond Lavoie et Claude Lavoie, tous forgerons et mécaniciens, du village de Saint-Jérôme, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes, sous le nom de \"Jos.Lavoie & Fils, Ltée.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jérôme (Mctabetchouan), district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(A.G.12933-54) Joseph C.Pardo Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of December, 1954, incorporating: Philip Fischel Vinebcrg, advocate, of Westmount, Arthur Franklin Garmaise, advocate, and Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, of Montréal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a real estate investment business, under the name of \"Joseph C.Pardo Ltd.\", with a total capital stock of $-10,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.12856-54) Jos.Lavoie & Fils, Ltée.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of December, 1954, incorporating : Joseph Lavoie, Dollard Lavoie, Roch Lavoie, Yvon Lavoie, Raymond Lavoie and Claude Lavoie, all blacksmiths and mechanics, of the village of Saint Jérôme, judicial district of Roberval, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers, under the name of \"Jos.Lavoie & Fils, Ltée.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Jérôme (Metabetchouan), judicial district of Roberval.Dated at the office of -the Attorney General, this third day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(P.G.12995-54) Kaymar Lumber Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six décembre 1954, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Aronotich et Abraham Shuster, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer dans aucune et toutes leurs spécialités le commerce comme exploiteurs de forêts, bûcherons, marchands de bois de construction et propriétaires de scierie, moulin à planer et moulin de pulpe, sous le nom de \"Kaymar Lumber Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40 actions ordinaires de $100 chacune et 360 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(A.G.12995-54) Kaymar Lumber Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December, 1954, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronotich and Abraham Shuster, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on in any and all their branches the business of loggers, lumbermen, lumber merchants and sawmill, planing-mill and pulpmill owners, under the name of \"Kaymar Lumber Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40 common shares of $100 each and into 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General. 198 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 8 (P.G.12334-54) Laboratoire Martin Inc.Martin Laboratories Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois décembre 1954, constituant en corpo-tion: Jean-Jacques Langlois, industriel, Robert-Claude Lamarre et Raymond-Robert Martin, ces deux derniers vendeurs, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants : Exercer le commerce de produits de laboratoires ou produits pharmaceutiques patentés, sous le nom de \"Laboratoire Martin Inc.\u2014 Martin Laboratories Inc.\", avec un capital total de S40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de §10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(A.G.12334-54) Laboratoire Martin Inc.Martin Laboratories Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of December 1954, incorporating: Jean Jacques Langlois, industrialist, Robert Claude Lamarre and Raymond Robert Martin, the two latter salesmen, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in laboratory products or licensed pharmaceutical products, under the name of \"Laboratoire Martin Inc.\u2014Martin Laboratories Inc.\", with a total capital of §40,000, divided into 2,000 common shares of §10 each and 2,000 preferred shares of §100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this third day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(P.G.11953-54) (A.G.11953-54) La Ligue des Propriétaires de Jonquière Inc.La Ligue des Propriétaires de Jonquière Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date, du sept décembre 1954, constituant en corporation sans capital-actions: Marcel Laliberté, opérateur, Louis-Georges Bergeron, gardien, Emile Lambert, gérant, Jean-Marie Lessard, dessinateur, Ulysse Ratthé, opérateur électricien, Nil Gagnon, électricien, et Donat Landry, cond.camion, tous de Jonquière, district de Chicoutimi, pour les objets suivants: Faire connaître les droits des propriétaires fonciers de la ville de Jonquière, sous le nom de \"La Ligue des Propriétaires de Jonquière Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de §10,000.Le siège social de la corporation sera à Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le sept décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12980-54) Landview Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sixième jour de décembre 1954, constituant en corporation: Samuel Hersh, John Bennett, également connu Bernetsky, marchands, tous deux de Montréal et Jack Laster, marchand d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles et exercer les affaires comme une compagnie de constructeurs et d'entrepreneurs, sous le nom de \"Landview Inc.\", avec un capital total de §50,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de §10 chacune et 4,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de §10 chacune.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of December 1954, to constitute as a corporation without share capital: Marcel Laliberté, operator, Louis Georges Bergeron, watchman, Emile Lambert, manager, Jean-Marie Lessard, draughtsman, Ulysse Ratthé, electrical operator, Nil Gagnon, electrician, and Donat Landry, truck driver, all of Jonquière, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes : To make known the rights of the land owners of the town of Jonquière, under the name of \"La Ligue des Propriétaires de Jonquière Inc.\".The amount to which the value of immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is §10,000.The head office of the Corporation will be at Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12980-54) Landview Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December, 1954, incorporating: Samuel Hersh, John Bennett, also known as Bernetsky, merchants, both of Montreal, and Jack Laster, merchant, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate and to carry on the business of a general construction and contracting company, under the name of \"Landview Inc.\", with a total capital stock of §50,000, divided into 1,000 common shares of a par value of §10 each and into 4,000 preferred shares of a par value of §10 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87,Jfo.3 199 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce sixième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.13061-54) La Société Historique Industrielle Inc.Industrial Historical Society Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du sept décembre 1954, constituant en corporation: L.-Yvon Dostie, Louis Mathieu, journalistes, Aline Lalonde, trésorière, épouse contractuel-lement séparée de biens de Louis Dostie, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, Paul Demers, journaliste, et Rita Caron, secrétaire, ces deux derniers des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'imprimeurs, lithograveurs et graveurs, exploiter des bibliothèques, sous le nom de \"La Société Historique Industrielle Inc.\u2014 Industrial Historical Society Inc.\", avec un capital total de §40,000, divisé en 4.000 actions de §10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 10S03, rue Berri, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.13013-54) Leather Garment Makers Inc.Avis est donné qu'en vertu -de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du septième jour de décembre 1954, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, Alan Golden, commis, et Larry Smith, comptable, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs et manufacturiers de vêtements pour hommes, femmes et enfants, sous le nom de \"Leather Garment Makers Inc.\", avec un capital total de §15,000, divisé en 50 actions ordinaires de §100 chacune et 100 actions privilégiées de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.12762-54) Les Ateliers de Soudure de Rimouski Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept décembre 1954, constituant en corporation: Ronaldo Raboin, notaire, André-P.Cas-grain, avocat, et Françoise Guévin, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Construction générale de bâtiments; atelier de soudure et de réparations générales, sous le nom de \"Les Ateliers de Soudure de Rimouski, Limi- The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.13061-54) La Société Historique Industrielle Inc.Industrial Historical Society Inc.Notice is herey given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of December, 1954, incorporating: L.Yvon Dostie, Louis Mathieu, journalists, Aline Lalonde, treasurer, wife contractually separate as to property, of Louis Dostie, and duly authorized by the latter for these present purposes, all of the city and judicial district of Montreal, Paul Demers, journalist, and Rita Caron, secretary, the latter two of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To operate as printers, lithographers and engravers, operate libraries, under the name of \"La Société Historique Industrielle Inc.\u2014 Industrial Historical Society Inc.\", with a total capital stock of §40,000, divided into 4,000 shares of §10 each.The head office of the company will be at 10S03, Berri Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13013-54) Leather Garment Makers Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of December, 1954, incorporating: Louis Orenstein, advocate, Alan Golden, clerk, and Larry Smith, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following * purposes : To act as contractors and manufacturers of men's women's and children's clothing, under the name of \"Leather Garment Makers, Inc.\", with a total capital stock of §15,000, divided into 50 common shares of §100 each and into 100 preferred shares of §100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General, (A.G.12762-54) Les Ateliers de Soudure de Rimouski Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of December, 1954, incorporating: Ronaldo Raboin, notary, André-P.Casgrain, advocate, and Françoise Guévin, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Rimouski, for the following purposes: General erection of buildings; soldering workshop and general repairs, under the name of \"Lès Ateliers de Soudure de Rimouski Limitée\", 200 r 'GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 tée\", avec un capital total de 820,000, divisé en 50 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune et en 150 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général,- le sept décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 390G2-o C.E.CANTIN.(P.G.13002-54) Les Immeubles Roslyn Limitée Roslyn Real Estate Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept décembre 1954, constituant en corporation: Edgar Armand, d'Outrcmont, Joseph-Adélard Fillion et Marc Fillion, de Montréal, tous comptables agréés, du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Les Immeubles Roslyn Limitée \u2014 Roslyn Real Estate Limited\", avec un capital total de 8125,000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.with a total capital stock of 820,000, divided into 50 common shares of a par value of 8100 each and into 150 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Rimouski, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this seVenth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13002-54) Les Immeubles Roslyn Limitée Roslyn Real Estate Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of December 1954, incorporating: Edgar Armand, of Outremont, Joseph Adélard Fillion and Marc Fillion, of Montreal, all chartered accountants, of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Les Immeubles Roslyn Limitée \u2014 Roslyn Real Estate Limited\", with a total capital stock of 8125,000, divided into 250 common shares of a par value of 8100 each and 1,000 preferred shares of a par value of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(P.G.12744-54) Les Quatre Laurcntiens Limitée The Four Laurcntians Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en'date du premier décembre 1954, constituant en corporation: Henri Beaulieu, avocat et conseil en Loi de la Reine, Léo Limoges, comptable, tous deux de Montréal, et Jean Beaulieu, avocat, d'Outrcmont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires et agir comme entrepreneurs généraux; exercer le commerce de construction, de matériaux de construction, d'entreposage et de transport, sous le nom de \"Les Quatre Laurentiens Limitée \u2014 The Four Laurentians Limited\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 1,000 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(A.G.12744-54) Les Quatre Laurentiens Limitée The Four Laurentians Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first of December, 1954, incorporating: Henri Beaulieu, advocate and Queen's Counsel, Léo Limoges, accountant, both of Montreal, and Jean Beaulieu, advocate, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business and operate as general contractors; to carry on a construction company, to deal in building materials, warehousing and transportation, under the name of \"Les Quatre Laurentiens Limitée \u2014 The Four Laurentians Limited\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 1,000 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(P.G.12815-54) L'Imprimerie Yamel Inc.Yamel Printing Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept décembre 1954, constituant en corporation: John Assad, marchand, Anita Charron (Gagnon), ménagère, épouse contractuellement séparée de biens de Georges Charron, et dûment (A.G.12815-54) L'Imprimerie Yamel Inc.Yamel Printing Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of December, 1954,v incorporating: John Assad, merchant, Anita Charron (Gagnon), housekeeper, wife contractually separate as to property of Georges Charron, and duly author- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.8 201 autorisée par lui aux fins des présentes, et Lorraine Chartrand, sténographe, fille majeure usant de ses droits, tous de Buckingham, district judiciaire de Hull, pour les objets suivants: Exploiter une imprimerie et exercer le commerce de papeterie et d'articles de nouveauté, sous le nom de \"L'Imprimerie Yamel Inc.\u2014Yamel Printing Inc.\", avec un capital total de §20,000.divisé en 2,000 actions ordinaires de §10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Buckingham, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le sept décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12839-54) Ludger Porlier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux décembre 1954, constituant en corporation: Jean-Paul Dansereau, avocat, Roland R.Beaudry, comptable, agréé, et Yvette Proven-cher, sténographe, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme marchand de fruits et légumes, sous le nom de \"Ludger Porlier Inc.\", avec un capital total de §40,000, divisé en 400 actions d'une valeur au pair de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 390G2-o C.E.CANTIN.(P.G.13168-54) Main Oka Mining Corporation (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt et unième jour de décembre 1954, constituant en corporation: Jean Mouette, avocat, de Longucuil, Richard Staines, comptable agréé, et Rita Angers, sténographe, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Main Oka Mining Corporation\" (No Personal Liabilitv), avec un capital total de §3,000,000, divisé en 3,000,000 d'actions de §1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt et unième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 % C.E.CANTIN.ized by him for these presents, and Lorraine Chartrand, stenographer, spinster, in use of her rights, all of Buckingham judicial district of Hull, for the following purposes: To operate a printing press and to deal in stationery and novelty articles, under the name of \"L'Imprimerie Yamel Inc.\u2014Yamel Printing Inc.\", with a total capital stock of §20,000, divided into 2,000 common shares of §10 each.The head office of the company will be at Buckingham, judicial district of Hull.Dated at the office of the Attorney General, this seventh dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12839-54) Ludger Porlier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of December, 1954, incorporating: Jean-Paul Dansereau, advocate, Roland R.Beaudry, chartered accountant, and Yvette Provencher, sténographie, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a fruit and vegctabel merchant, under the name of \"Ludger Porlier Inc.\", with a total capital stock of §40,000, divided into 400 shares of a par value of §100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13168-54) Main Oka Mining Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of December, 1954, incorporating: Jean Monette, barrister, of Longucuil, Richard Staines, chartered accountant, and Rita Angers, stenographer, spinster, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Main Oka Mining Corporation\" (No Personal Liability), with a total capital stock of 83,000,000, divided into 3,000,000 shares of §1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General. 202 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 8 (P.G.12934-54) Manufacture de Boîtes de Saint-Hyacinthe Limitée Saint-Hyacinthe Paper Box Manufacturing Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six décembre 1954, constituant en corporation: Mandus Bienvenue, industriel, Cécile Rivard, s ténographe, fdle majeure, tous deux de Saint-Hyacinthe, et Marcel Lcmonde, avocat, de Saint-Liboire, tous du district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de boîtes de carton, sous le nom de \"Manufacture de Boîtes de Saint-Hyacinthe Limitée \u2014 Saint-Hyacinthe Paper Box Manufacturing Limited\", avec un capital total de $100,0C0, divisé en 250 actions communes de $100 chacune et en 750 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 275, rue St-Antoine, La Providence, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.13072-54) Marauda Lustre Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix décembre 1954, constituant en corporation: Henri Clément, Paul-Henri Guimont, courtiers en obligations, et J.-Emile Dion, gérant de manufacture, tous de la cité de Sillery, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants : Exercer l'industrie et le commerce de teinturiers et de nettoyeurs de fourrures, sous le nom de \"Maranda Lustre Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 800 actions ordinaires d'une valeur au pair de $25 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera «a Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12741-54) Marcitta Sportswear Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sixième jour de décembre 1954, constituant en corporation: Louis Orenstein, Egbert Earl Cockerton, avocats, Alan Golden, commis, et Larry Smith, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements pour enfants, dames, jeunes filles et hommes, sous le nom de \"Marcitta Sportswear Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaire de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.(A.G.12934-54) Manufacture de Boîtes de Saint-Hyacinthe Limitée Saint-Hyacinthe Paper Box Manufacturing Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December, 1954, incorporating: Mandus Bienvenue, industrialist, Cécile Rivard, stenographer, spinster, both of Saint-Hyacinthe, and Marcel Lemonde, advocate, of Saint-Liboire, all of the judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To carry on the business of an deal in cardboard boxes, under the name of \"Manufacture de Boîtes de Saint-Hyacinthe Limitée \u2014 Saint-Hyacinthe Paper Box Manufacturing Limited\", with a total capital stock of $100,000, divided into 250 common shares of $100 each and into 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 275 St-Antoine Street, La Providence judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13072-54) Maranda Lustre Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of December, 1954, incorporating: Henri Clément, Paul-Henri Guimont, stock brokers, and J.-Emile Dion, factory manager, all of the city of Sillery, judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of and operate as dyers and cleaners in furs, under the name of \"Maranda Lustre Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 800 common shares of a par value of $25 each and into 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12741-54)_ Marcitta Sportswear Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December, 1954, incorporating: Louis Orenstein, Egbert Earl Cockerton, advocates, Alan Golden, clerk, and Larry Smith, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in children's, ladies', young women's and men's wear, under the name of \"Marcitta Sportswear Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 203 Daté du bureau du Procureur général, ce sixième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.12900-54) Marion Bros.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du premier décembre 1954, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch et Abraham Sinister, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger des affaires comme agents d'immeubles et agents pour la vente d'entreprises commerciales, sous le nom de \"Marion Bros.Inc.\", avec un capital-actions divisé en 100 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.12977-54) Médéric Pcrrier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six décembre 1954, constituant en corporation: Marcel Fortin, marchand, de Hemmingford, district judiciaire de Beauharnois, André Richer, marchand, de Varennes, district judiciaire de Richelieu, et Marcel Morin, notaire, des cité et district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de produits alimentaires, de nourritures d'animaux de ferme, d'animaux à fourrure et de volailles, sous le nom de \"Médéric Perrier Inc.\", avec un capital total de $30,000, divisé en 300 actions communes d'une valeur nominale ou au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.13042-54) Normandie Construction Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie dè la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dixième jour de décembre 1954, constituant en corporation: Milton Lowen Klein, avocat, Ethel Schwisberg, Mildred Brown et Frances Herscovitz, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Ériger, améliorer, transformer des constructions et faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Normandie Construction Limited\", avec un capital total de $200,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $100 chacune et 1,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General, (A.G.12900-54) Marion Bros.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December, 1954, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch and Abraham Sinister, all advocates, of the city and judicial district of the following purposes: To carry on the business of real estate agents, of agents for sale of commercial business, under the name of \"Marion Bros.Inc.\", with a capital stock divided into 100 common shares of no par value.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o \" Deputy Attorney General.(A.G.12977-54) Médéric Perrier Inc.Notice is hereby given that under Part I of tire Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December, 1954, incorporating: Marcel Fortin, merchant, of Hemmingford, judicial district of Beauharnois, André Richer, merchant, of Varennes, judicial district of Richelieu, and Marcel Morin, notary, of the city and judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To manufacture and deal in foodstuffs, stock feed for farm animals, fur-bearing animals and fowl under the name of \"Médéric Perrier Inc.\", with a total capital stock of $30,000, divided into 300 common shares of a nominal or par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13042-54) Normandie Construction Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of December, 1954, incorporating: Milton Lowen Klein, advocate, Ethel Schwisberg, Mildred Brown and Frances Herscovitz, secretaries, spinsters, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To erect, improve, alter buildings and deal in building materials, under the name of \"Normandie Construction Limited\", with a total capital stock of $200,000, divided into 1,000 common shares of $100 each and into 1,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 204 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour de décembre 1954.L'Assistant-procu reu r général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.13069-54) Ouellet & Arcand Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1954, constituant en corporation: Maurice Gagné, C.R., Jacques Flynn, C.R., et Julien Cliouinard, tous avocats, des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs généraux ou sous-entrepreneurs, sous le nom de \"Ouellet & Arcand Inc.\", avec un capital divisé en 500 actions communes d'une valeur au pair ou nominale de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12988-54) Parc St-Claude Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre décembre 1954, constituant en corporation: Louis-Germain Castonguay, arpenteur géomètre et ingénieur forestier, de Loretteville, Jules-Pierre Castonguay, arpenteur-géomètre, de Québec, et Bernard Samson, notaire, de Sainte-Foy, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneur général et de marchand de matériaux de construction, sous le nom de \"Parc St-Claude Ltée\", avec un capital total de 8125,000, divisé en 250 actions communes de 8100 chacune et en 10,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera au soins de L.G.Castonguay, rang St-Claude, Loretteville, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le quatre décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12997-54) Parfumerie Ambrum Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux décembre 1954, constituant en corporation: Jean-H.Deslauriers, avocat, d'Outremont, Roma Cousineau, avocat, de Verdun, et Denyse Lachan-ce, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de parfums, cosmétiques et autres produits de beauté, sous le nom de \"Parfumerie Ambrum Inc.\", avec un capital total de 820,000, divisé en 200 actions de 8100 chacune.Le -siège social de la compagnie sera à 2065J rue Curatcau, Montréal, district judiciaire de Montréal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.13069-54) Ouellet & Arcand Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1954, incorporating: Maurice Gagné, Q.C., Jacques Flynn, Q.C., and Julien Chouinard, all advocates, of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To operate as general contractors or subcontractors, under the name of \"Ouellet & Arcand Inc.\", with a capital stock divided into 500 common shares of a par or nominal value value of S100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12988-54) Parc St-Claude Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of December, 1954, incorporating: Louis-Germain Castonguay, surveyor and forestry engineer, of Loretteville Jules-Pierre Castonguay, surveyor, of Quebec, and Bernard Samson, notary, of Sainte-Foye, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a general contractor and merchant in building materials, under the name of \"Parc St-Claude Ltée\", with a total capital stock of 8125,000, divided into 250 common shares of $100 each and into 10,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be in the care of L.G.Castonguay, range St-Claude, Loretteville, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12997-54) Parfumerie Ambrum Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of December 1954, incorporating: Jean-H.Deslauriers, advocate, of Outremont, Roma Cousineau, advocate, of Verdun, and Denyse Lachance, secretary, spinster, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: \u2022 To manufacture and deal in perfumes, cosmetics and other beauty products, under the name of \"Parfumerie Ambrun Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at 2065, Curateau Street, Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 205 Daté du bureau du Procureur général, le deux décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 390G2-o C.E.CANTIN.(P.G.12938-54) Placements Vicalco Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec îles lettres patentes, en date du sept décembre 1954, constituant en corporation: J.-Victor Côté, courtier, Gérard Doyon, avocat, tous deux de Québec, et Guy Dorion, avocat, de Sillery, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placements, sous le nom de \"Placements Vicalco Inc.\", avec un capital total de SI00,000, divisé en 1,000 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le sept décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 390G2-o C.E.CANTIN.(P.G.13038-54) Portneuf Automobiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept décembre 1954, constituant en corporation: L.E.Langis Galipcault, avocat et conseil en loi de la Reine, Antonio Leclerc, comptable publique accrédité, et Jeanne Déchcnc, sténographe, célibataire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de véhicules automobiles et agir comme garagistes, sous le nom de \"Portneuf Automobiles Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 800 actions ordinaires de $5 chacune et en 3,200 actions privilégiées de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Cap Santé, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le sept décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12965-54) Prestige Shoes Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois décembre 1954, constituant en corporation: Paul Marcoux, voyageur de commerce, René Boucher, industriel, de Montréal, et Lawrence Grenier, chef de département, de Pointe-Claire, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de chaussures et d'articles en cuir, sous le nom de \"Prestige Shoes Ltd.\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 1,000 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12938-54) Placements Vicalco Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor 'of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of December, 1954, incorporating: J.-Victor Côté, broker, Gérard Doyen, advocate, both of Quebec, and Guy Dorion, advocate, of Sillery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on business as a holding company under the name of \"Placements Vicalco Inc.\", with a total capital stock of $103,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this seventh dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13038-54) Portneuf Automobiles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of December 1954, incorporating: L.E.Langis Galipcault, advocate and Queen's Counsel, Antonio Leclerc, accredited public accountant, and Jeanne Déchêne, stenographer, spinster, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in motor vehicles and act as garage-keepers, under the name of \"Portneuf Automobiles Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 800 common shares of $5 each and 3,200 preferred shares of $5 each.The head office of the company will be at Cap Santé, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12965-54) Prestige Shoes Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of December, 1954, incorporating: Paul Marcoux, commercial traveller, René Boucher, industrialist, of Montreal, and Lawrence Grenier, departmental manager, of Pointe-Claire, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in footwear and leather goods, under the name of \"Prestige Shoes Ltd.\", with a total capital stock of $100,-000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of December 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General. 206 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 8 (P.G.12958-54) * Quebec Industrial Supply Co.Ltd.Cic* d'Outillage Industriel de Québec Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier décembre 1954, constituant en corporation: Paul-André Morin, voyageur, Benoit Boulanger, notaire, tous deux de Québec, et Aurélien Gravel, industriel, de Loretteville, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'outillage et machinerie, sous le nom de \"Quebec Industrial Supply Co.Ltd.\u2014 Cie d'Outillage Industriel de Québec Ltée\", avec un capital total de S40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(A.G.12958-54) Quebec Industrial Supply Co.Ltd.Cie d'Outillage Industriel de Québec Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December, 1954, incorporating: Paul-André Morin, traveller, Benoit Boulanger, notary, both of Quebec, and Aurélien Gravel, industrialist, of Loretteville, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in machinery and supplies, under the name of \"Quebec Industrial Supply Co.Ltd.\u2014 Cie d'Outillage Industriel de Québec Ltée\", with a total capital stock of $40.000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(P.G.13067-54) Rcvcle Infants Wear Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du treizième jour de décembre 1954, constituant en corporation: Albert Malouf, avocat, Lily Malouf, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal et Peter Shorteno, avocat, de ville St-Laurent, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements et tissus pour articles vestimentaires, sous le nom de \"Rcvcle Infants Wear Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4652 rue Rivard, Montréal, district judiciaire do Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce treizième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(A.G.13067-54) Révèle Infants Wear Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1954, incorporating: Albert Malouf, advocate, Lily Malouf, secretary, spinster of the full age of majority, both of Montreal, and Peter Shorteno, advocate, of ville St.Laurent, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel and materials for wearing apparel, under the name of \"Revele Infants Wear Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 4652 Rivard Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(P.G.12978-54) Richelieu Heights Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date, du sixième jour de décembre 1954, constituant en corporation: Philip F.Vineberg, Neil F.Phillips, avocats, Mclvin L.Rothman, étudiant en droit, de Westmount, David Goodman, avocat, de Hampstead, et Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et développer des propriétés immobilières, sous le nom de \"Richelieu Heights Inc.\", avec un capital total de $40,500, divisé en 100 actions ordinaires de $5 chacune et 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce sixième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(A.G.12978-54) Richelieu Heights Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December, 1954, incorporating: Philip F.Vineberg, Neil F.Phillips advocates, Melvin L.Rothman, law student, of Westmount, David Goodman, advocate, of Hampstead, and Yvonne Bélanger, secretary, -fille majeure, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and develop immoveable property, under the name of \"Richelieu Heights Inc.\", with a total capital stock of $40,500, divided into 100 common shares of $5 each and into 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 32nd, 1956, Vol.87, No.3 207 (P.G.13065-54) Riviera Land Development Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du treizième jour de décembre 1954, constituant en corporation: Nathan Schreiber, Azar Goldin et Elias Shapiro, tous marchands, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir, faire le commerce et le négoce de propriétés immobilières, sous le nom de \"Riviera Land Development Limited\", avec un capital total de 850,000, divisé en 500 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce treizième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.12833-54) Rollet Uranium Co.Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux décembre 1954, constituant en corporation: Gilbert Ronaldo Provcnchcr, camionneur, Céles-tin Guertin, industriel, tous deux de Rouyn, et René Bédard, avocat, de Noranda, tous du district judiciaire de Rouyn-Noranda, pour les objets suivants: Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Rollet Uranium Co.Ltd.\" (No Personal Liability), avec un capital total de 83,000,000, divisé en 3,000,000 d'actions de SI chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Rouyn, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Daté du bureau du Procureur général, le deux décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12987-54) Rusco-Vallée Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois décembre 1954, constituant en corporation: Mozart R.Vallée, marchand de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, Julius Lipson, distributeur, Pauline Bélanger, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, et Muguette Stonehouse, secrétaire, fille majeure, de Verdun, ces trois derniers, du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants; Agir comme marchand des produits \"Rusco\", portes, fenêtres, appareils, accessoires et autres articles, sous le nom de \"Rusco-Vallée Inc.\", avec un capital total de 820,000, divisé en 200 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.(A.G.13065-54) Riviera Land Development Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1954, incorporating: Nathan Schreiber, Azar Goldin and Elias Shapiro, all merchants, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal in and with immoveable property, under the name of \"Riviera Land Development Limited\", with a total capital stock of 850,000, divided into 500 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.12833-54) Rollcl Uranium Co.Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec bearing date the second day of December, 1954, incorporating: Gilbert Ronaldo Provencher, trucker, Célestin Guertin, industrialist, both of Rouyn, and René Bédard, advocate, of Noranda, all of the judicial district of Rouyn-Noranda, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Rollet Uranium Co.Ltd.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of S3,000,000, divided into 3,000,000 shares of SI each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Rouyn, judicial district of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12987-54) Rusco-Vallée Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of December 1954, incorporating: Mozart R.Vallée, merchant of Sherbrooke, judicial district of Saint Francis, Julius Lipson, distributor, Pauline Bélanger, secretary, fillc majeure, both of Montreal, and Muguette Stonehouse, secretary, fille majeure, of Verdun, the three latter of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as a dealer in \"Rusco\" products, doors, windows, apparatus, accessories and other articles, under the name of \"Rusco-Vallée Inc.\", with a total capital of $20,000, divided into 200 shares of S100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis. 20S GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° S Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 390G2-o C.E.CANTIN.(P.G.13149-54) Sofacr Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingtième jour de décembre 1954, constituant en corporation : Ernest William Mockridgc, gérant, Clifford George Meek, teneur de livres, et Cecil Bruce Cooke, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et en général celui des produits de l'agriculture, des forêts, des mers et de l'air, sous le nom de \"Sofaer Investments Inc.\", avec un capital total de §40,000, divisé en 4,000 actions d'une valeur au pair de §10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingtième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 390G2 C.E.CANTIN.(P.G.12963-54) Spear Packing Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du premier jour de décembre 1954, constituant en corporation: Ira Spier, manufacturier, François Morel, avocat et Rita Savaria, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'importateurs, exportateurs, manufacturiers, vendeurs, cultivateurs, producteurs, marchands ou commerçants de fruits, légumes et produits alimentaires, sous le nom de \"Spear Packing Co.Ltd.\", avec un capital de $25,000, divisé en 500 actions ordinaires de §10 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Terre-bonne, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, ce premier jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.13016-54) S.Rossini & Sons Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onzième jour de décembre 1954, constituant en corporation: Rodney Alexander Patch, Kenneth Charles Mackay, Donald Edward MacKenzie et Jean Gagnon, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Diriger et exercer le commerce de constructeurs, entrepreneurs-plâtriers et entrepreneurs aux fins de construction, érection, transformation, et réparation, sous le nom de \"S.Rossini & Sons Ltd.\", avec un capital-actions divisé en 8,000 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à 1055 avenue Blair, Montréal, district judiciaire de Montréal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.13149-54) Sofacr Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec bearing date the twentieth day of December, 1954, incorporating: Ernest William Mockridge, manager, Clifford George Meek, bookkeeper, and Cecil Bruce Cooke, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: company and to generallydcalintheproductsO To carry on the business of an investment company and to generally deal in the products of agriculture, the forest, the seas and air, under the name of Sofaer Investments Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 shares of the par value of §10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.12963-54) Spear Packing Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December, 1954, incorporating: Ira Spier, manufacturer, François Morel, advocate, and Rita Savaria, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of importers, exporters, manufacturers, venders, growers, producers of and merchants or dealers in fruits, vegetables and foods, under the name of \"Spear Packing Co.Ltd.\", with a total capital stock of §25,000, divided into 500 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Terrebonne, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.13016-54) S.Rossini & Sons Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1954, incorporating: Rodney Alexander Patch, Kenneth Charles Mackay, Donald Edward MacKenzie and Jean Gagnon, all advocates, of the city and \"judicial district of Montreal, for the following purposes : To conduct and carry on the business of builders, plastering contractors and contractors for the purpose of building, erecting, altering, repairing, under the name of \"S.Rossini & Sons Ltd.\", with a capital stock diviced into 8,000 shares having no nominal or par value.The head office of the company will be at 1055 Blair Avenue, Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 209 Daté du bureau du Procureur général, ce onzième jour de décembre 1954.L'Assistant -procureur général, 390G2 C.E.CANTIN.(P.G.12814-54) Superior Asbestos Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinq novembre 1954, constituant en corporation: Philip Fischel Vineberg, Neil Franklin Phillips, avocats, Melvin Rothman, étudiant, de Westmount, David Goodman, avocat, et Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir de l'amiante, des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Superior Asbestos Ltd.\" (No Personal Liability), avec un capital total de 83,000,000, divisé en 3,000,000 d'actions d'une valeur au pair de 81 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au-delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour des actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq novembre 1954., L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.12979-54) Italian & Frère Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six décembre 1954, constituant en corpora-, tion: Jules Dupré, C.R., avocat, d'Outremont Raymond Lette, clerc, d'Hampstead, et Jeanne-Françoise Raymond, secrétaire, célibataire, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de bois, bois à pâte, pâte à bois et produits divers de même nature, ainsi que de matériaux de construction, articles de quincaillerie, marchandises sèches, .appareils électriques et articles de ménage, jouets, sous le nom de \"Trahan & Frère Inc.\", avec un capital total de 8180,000, divisé en 1,300 actions communes de $100 chacune et en 500 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12787-54) Turpin Motors Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinquième jour de novembre 1954, constituant en corporation: Philip F.Foran, avocat, Conseil en Loi de la Reine, Marguerite R.Spraggon, secrétaire, épouse séparée de biens de Joseph Herbert Spraggon et dans l'exercice Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.12814-54) Superior Asbestos Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of November, 1954, incorporating: Philip Fischel Vincberg, Neil Franklin Phillips, advocates, Melvin Rothman, student, of Westmount, David Goodman, advocate, and Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for asbestos, mines and minerals and deal with same, under the name of \"Superior Asbestos Ltd.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of 83,000,000, divided into 3,000,000 shares of a par value of 81 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.12979-54) Trahan & Frère Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December, 1954, incorporating: Jules Dupré, Q.C., advocate, of Outrcmount, Raymond Lette, clerk, of Hampstead, and Jeanne-Françoise Raymond, secretary, bachelor, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in wood, pulpwood, wood pulp, and divers products of the same kind, as well as building materials, articles of hardware, dry-goods, electrical appliances and household articles, toys, under the name of \"Trahan & Frère Inc.\", with a total capital stock of 8180,000, divided into 1,300 common shares of S100 each and into 500 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Saint-John, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12787-54) Turpin Motors Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of November, 1954, incorporating: Philip F.Foran, advocate, one of Her Majesty's Counsel, Marguerite R.Spraggon, secretary, wife separate as to property and in the exercise of her rights according to the laws of England, 210 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1965, Tome 87, N° 3 de ses droits conformément aux lois d'Angleterre, y possédant leur domicile conjugal, tous deux d'Ottawa, William R Hadley, avocat, de Rock-liffe, Park, tous de Providence, Ontario et Katie H.Parker, secrétaire, veuve non-remariée du défunt Herbert Arnold Parker, de Deschênes, district judiciaire de Hull, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'automobiles et autres véhicules ainsi que leurs accessoires, sous le nom de \"Turpin Motors Ltée\", avec un capital-actions divisé en 2,500 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et 2,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de §10 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la ville de Gatineau, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-cinquième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39002 C.E.CANTIN.(P.G.12826-54) United Builders Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf décembre 1954, constituant en corporation: Jack Lighstone, Marvin Riback, avocats, et Êlie M.Solomon, notaire, tous des' cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Négocier des immeubles et des propriétés réelles; exercer le commerce comme entrepreneurs et constructeurs, sous le nom de \"United Builders Co.Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4992, nie Prince of Wales, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(P.G.13029-54) Verdun Dyeing Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sixième jour de décembre 1954, constituant en corporation: Irwin A.Frankel, avocat, de ville Mont-Royal, Louis M.Benjamin, avocat, de Montréal, et Louis Freedman, avocat, de Hampstead, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et teindre et faire le commerce général du coton, laine, nylon et autres tissus sous le nom de \"Verdun Dyeing Co.Ltd.\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 300 actions ordinaires de 8100 chacune et 700 actions privilégiées et $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce sixième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.their marital domicile of Herbert Joseph Spraggon, both of Ottawa, William F.Hadley, advocate, of Rockcliffe Park, all of the Province of Ontario, and Katie H.Parker, secretary, unremarried widow of the late Herbert Arnold Parker, of Deschênes, judicial district of Hull, for the following purposes : To manufacture and deal in automobiles and other vehicles and their accessories, under the name of \"Turpin Motors Ltée\", with a capital stock divided into 2,500 common shares without nominal or par value and into 2,500 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at the town of Gatineau, judicial district of Hull.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.12826-54) United Builders Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of December, 1954, incorporating: Jack Light-stone, Marvin Riback, advocates, and Élie M.Solomon, notary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate and real property; to carry on business as contractors and builders, under the name of \"United Builders Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 4992 Prince of Wales Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.(A.G.13029-54) Verdun Dyeing Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December, 1954, incorporating: Irwin A.Frankel, advocate, of the town of Mount Royal, Louis M.Benjamin, advocate, of Montreal, and Louis Freedman, advocate, of Hampstead, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business of manufacturing, dyeing, and generally dealing in cotton, wool, nylon and other fabrics, under the name of \"Verdun Dyeing Co.Ltd.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 300 common shares of $100 each and into 700 preferred shares of $100 each.The head office of the company willXbe at Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 211 (P.G.12871-54) Young-at-Heart Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du septième jour de décembre, 1954, constituant en corporation : Eddie Singer, Ronald Wexelman, manufacturiers de Montréal, et Sydney Rubin, manufacturier, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements de sport pour dames, jeunes filles et enfants, sous le nom de \"Young-at-Heart Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 4,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour de décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062 C.E.CANTIN.(A.G.12871-54) Young-at-Heart Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of December, 1954, incorporating: Eddie Singer, Ronald Wexelman, manufacturers, of Montreal, and Sydney Rubin, manufacturer, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in ladies', teens' and children's sportswear, under the name of \"Young-at-Heart Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 4,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062-o Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent (P.G.10960-54) Central Office Equipment Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix décembre 1954, à la compagnie \"George D.Gravel Co.Ltd\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 13 avril 1954, changeant son nom en celui de \"Central Office Equipment Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général, le dix décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12718-54) Congregation Good Heart: Congregation Yetev Lav Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trente novembre 1954, à la corporation \"Congregation Good Heart: Congregation Yetev Lav\", étendant ses pouvoirs, à savoir: augmentant le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder de $21,000 à $100,000.Daté du bureau du Procureur général, le trente novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12784-54) Globe Paper Box Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du deux décembre 1954, à la compagnie \"Globe Paper Box Co.Limited\", augmentant son capital de $69,000 à $300,000: (A.G.10960-54) Central Office Equipment Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December tenth 1954, to the company \"George D.Gravel Co.Ltd\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated April 13, 1954, changing its name to that of \"Central Office Equipment Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of December 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12718-54) Congregation Good Heart: Congregation Yetev Lav Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the thirtieth day of November 1954, to the corporation \"Congregation Good Heart: Congregation Yetev Lav\", extending its powers, to wit: increasing the amount to which, is limited the value of immoveable property which the corporation may hold from the sum of $21,000 to $100,000.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of November 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12784-54) Globe Paper Box Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December second, 1954, to the company: \"Globe Paper Box Co.Limited\", increasing its capital stock from $69,000 to $300,000: the additional 212 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 le capital-actions additionnel étant divisé en 310 actions ordinaires et en 2000 actions privilégiées de S100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le deux décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o G.ti.CANTIN.(P.G.10641-54) J.E.McComber Furs Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quatorze décembre 1954, à la compagnie \"J: E.McComber Furs Inc.\", convertissant 1,300 actions ordinaires non émises de son capital-actions autorisé, d'une valeur au pair de SI00 chacune, en 1,300 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.11673-54) Lachulc Golf & Country Club Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du cinq octobre 1954, à la compagnie \"Le Club de Golf de Lachute Limitée \u2014 The Lachute Golf Club Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 10 octobre 1924:1 ° changeant son nom en celui de \"Lachute Golf & Country Club Limited\"; 2° augmentant son capital de $19,000 à $120,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 1010 actions de 8100 chacune.Daté du bureau «lu Procureur général, le cinq octobre 1954.L'Assistant-procu reur général, 39062-b ' C.E.CANTIN.(P.G.12972-54) La Compagnie d'Entreposage de G ran by Limitée Granhy Warehousing Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du neuf décembre 1954, à la compagnie \"Granby Steel Works Corporation\", constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date «lu 14 février 1950, sous le nom originaire de \"The General Metal Works Corporation\", et par lettres patentes supplémentaires en date du 2 mai 1950, changeant ledit nom originaire en celui de \"Granby Steel Works Corporation\", a) changeant de nouveau son nom en celui de \"La Compagnie d'Entreposage «le Granby Limitée \u2014 Granby Warehousing Company Limited\"; b) étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.capital slock being divided into 310 common shares and into 2,000 preferred shares of S100 each.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.10041-54) J.E.McComber Furs Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fourteenth day of December 1954, to the company \"J.E.McComber Furs Inc.\", converting 1,300 unissued common shares of its authorized share capital, of a par value of S100 each, into 1,300 preferred shares of a par value of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of December 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.11673-54) Lachute Golf & Country Club Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated October fifth, 1954, to the company \"Le Club «le Golf de Lachute Limitée \u2014 The Lachute Golf Club Limited\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated October 10, 1.changing its name into that of \"Lachute Golf & Country Club Limited\"; 2.increasing its capital from S 19,000 to $120,000: the additional capital stock being divided into 1010 shares of SI00 each.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of October, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12972-54) La Compagnie d'Entreposage de Granby Limitée Granby Warehousing Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December ninth, 1954, to the company \"Granby Steel Works Corporation\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated February 14, 1950, under the original name of \"The General Metal Works Corporation\", and by supplementary letters patent dated May 2nd, 1950, changing the said original name into that of \"Granby Steel Works Corporation\", a) changing again its name into that of \"La Compagnie d'Entreposage de Granby Limitée \u2014 Granby Warehousing Company Limited\"; b) extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1965, Vol.87, No.3 213 (P.G.13008-54) Northmount Agencies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quatorze décembre 1954, à la compagnie \"Dunau Travel Bureau Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 16 février 1953, changeant son nom en celui de \"Northmount Agencies Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le quatorze décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12670-54) Perco Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du deux décembre 1954, à la compagnie \"Perco Limited\", 1° augmentant son capital de $20,000 à $120,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 1000 actions privilégiées de $100 chacune; 2° étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le deux décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12884-54) Sterling 5c.to $1.00 Stores Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du premier décembre 1954, à la compagnie \"Sterling 5c to $1.00 Stores Limited\", augmentant son capital de $149,900 à $299,900: le capital-actions additionnel étant divisé en 1,500 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 21 _ ai-Québec, le 5 janvier 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Concernant des modifications à la Section \"A\" du décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région deMontréal.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective, (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de plombier et de poseur d'appareils de chauffage, rendue obligatoire par la section \"A\" du décret numéro 1021 du 10 septembre 1953, relatif à l'in- (A.G.13008-54) Northmount Agencies Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fourteenth day of December 1954, to the company \"Dunau Travel Bureau Ltd.\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated February 16, 1953, changing its name to that of \"North-mount Agencies Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of December 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12670-54) Perco Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December second, 1954, to the company \"Perco Limited\", 1.increasing its capital stock from $20,000, to $120,000: the additional capital stock being divided into 1,000 preferred shares of $100 each; 2.extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12884-54) Sterling 5c.to $1.00 Stores Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December first, 1954, to the company \"Sterling 5c to $1.00 Stores Limited\", increasing its capital stock from $149,900 to $299,900: the additional capital stock being divided into 1,500 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 21 Quebec, January 5th, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments to part \"A\" of the decree relating to the construction industry and trades in the region of Montreal.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the plumbing and steam-fitting trades, rendered obligatory by part \"A\" of the decree No.1021 of September'10th, 1953, relating to the construction industry and trades 214 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 dustrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal, amendé par les arrêtés numéros 1257-C et 1378-A des 11 novembre et 23 décembre 1953, 192-A, 191-G, 851-A et 894-C des 11 mars, 21 août et 2 septembre 1954, ont présenté au Minisire du Travail une requête à l'effet de modifier ladite section \"A\"; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 13 novembre 1954; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que l'article XXII dudit décret numéro 1021, désigné sous le titre \"Section \"A\", soit remplacé par les dispositions suivantes: Dispositions spéciales et complémentaires relatives à certains métiers Section \"A\" \"XXII.Règlement spéciaux relatifs- aux métiers de ploml/icr, poseur d'appareils de chauffage, soudeur en tuyauterie et mécanicien en tuyauterie: a) Juridiction professionnelle: Le présent article s'applique à tout travail visé par les sous-paragraphes \"a\" et \"d\" du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des Mécaniciens en tuyauterie (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 173) et au règlement numéro 1341 de la cité de Montréal et régit tout travail exécuté à l'intérieur ou à l'extérieur de la boutique.Cependant, le présent article ne régit pas: 1.les poseurs de brûleurs à l'huile; 2.les ouvriers préposés à la construction de canalisation d'égoûts; 3.Les salariés permanents tel que définis par la Loi de la convention collective, excepté lorsqu'ils exécutent des travaux de construction nouvelle.4.Les personnes visées par la Loi des mécaniciens de machines fixes (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 178 et amendements).5.Les personnes visées par la Loi concernant les électriciens et les installations électriques (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 172 et amendements).b) Taux minima de salaires: Les taux minima de salaires sont les suivants: Entrepreneur maître-plombier, maître poseur d'appareils de chauffage travaillant comme salarié et détenteur de la licence, qu'il utilise ses outils ou agisse comme contremaître ou remplisse toute autre fonction de surveillance: par heure.S 3.00 par semaine.100.00 Par heure Compagnon-plombier, poseur d'appareils de chauffage mécanicien en tuyauterie et soudeur en tuyauterie.$2.05 Compagnon junior.1.55 Apprentis: 1ère année.0.80 2ème année.0.95 3cmc année.1.15 4ème année.1.20 Chauffeur de camion de service: (Sans limitation quotidienne de la durée du travail) par semaine.35.00 Contremaître en charge de dix compagnons ou plus: $0.25 de plus l'heure que le taux du compagnon.A compter du 1er juin 1955: les ajustements suivants devront être faits pour les catégories de salariés ci-après indiquées: in the region of Montreal, amended by Orders in Council Nos.1257-C and 1378-A of November llth and December 23rd, 1953.192-A, 191-G, 851-A and 894-C of March llth, August 21st and September 2nd, 1954, have submitted to the Minister of Labour a petition to amend the said part \"A\"; Whereas the said petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of November 13th, 1954; Whereas the objections thereto have been duly considered, as required by the Act; It is ordered, therefore, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That section XXII of the sait! decree, No.1021, headed \"Part \"A\", be replaced by the following provisions: Special and complementary provisions respecting various trades Part \"A\" \"XXII.Special regulations respecting the trades of plumber, stcamfitter, pipe welder and pipe mechanic: a) Professional jurisdiction: This section applies to all work governed by paragraphs \"a\" and d\" of subsection 2 of section 2 of the Pipe Mechanics Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 173) and by by-law Number 1341 of the city of Montreal and applies to all work, whether inside or outside the shop.However, the present section does not apply to: 1.oil burner mechanics; 2.workers engaged in the construction of water-mains and sewers; 3.permanent employees, as defined in the Collective Agreement Act, except when engaged in new construction operations.4.persons governed by the Stationary En-ginemen's Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 178 ami amendments).5.persons governed by the Electricians and Electrical Installations Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 172 and amendments).b) Minimum wage rates: The minimum rates of wages are the following: Master Plumber and Master Heating Contractor working as an employee and holding the license, whether working with his tools or as foreman or in any other supervisory capacity: per hour.S 3.00 per week.100.00 Per hour Journeyman in plumbing, heating, pipe fitting and pipe welding.S2.05 Junior Journeyman.1.55 Apprentices: 1st year.0.80 2nd year.0.95 3rd year.1.15 4th year.1.20 Truck drivers (service trucks) (Without daily limitation as to hours of work).35.00 \u2022 Foreman in charge of ten or more journeymen shall be paid an additional $0.25 per hour above the journeyman's rate.From June 1st 1955, the following readjustments shall be made for the following categories of employees: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 215 Compagnon-plombier, poseur d'appareils de chauffage, mécanicien en tuyauterie et soudeur en tuyauterie.2.10 Compagnon junior.1.60 Apprentis: 3ème année.1.20 4ème année.1.25 A compter du 1er octobre 1955, les ajustements suivants devront être faits par la catégorie de salariés ci-après indiqués: Compagnon-plombier, poseur d'appareils de chauffage, mécanicien en tuyauterie et soudeur en tuyauterie.2.12 Paiement des salaires: Tous les salariés doivent être payés en espèces ou par chèque accepté.c) Durée du travail: La durée maximum du travail des ouvriers qualifiés et des apprentis est de huit (8) heures par jour, réparties entre 8.00 ajn.et 5.00 p.m< les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, le tout devant constituer un maximum de quarante (40) heures par semaine.d) Travail supplémentaire: 1.Tout travail exécuté le Premier de l'an, l'Epiphanie, le Vendredi-Saint, le 24 mai, la Saint-Jean-Baptiste, le Jour de la Confédération, la fête du Travail, le jour d'Action-dc-Grâces, le jour de Noël, la fête de l'Immaculée-Conccption, la Toussaint, le jour de l'Ascension et les dimanches, est rémunéré au taux de salaire double.2.Tout travail exécuté le samedi doit être payé au taux de salaire et demi pour les quatre premières heures de travail et au taux de salaire double pour toute heure additionnelle.3.Tout travail exécuté entre 5.00 p.m.et 10.00 p.m.est considéré comme travail supplémentaire et payé à raison de salaire et demi.4.Tout travail exécuté entre 10.00 p.m.et 8.00 a.m.doit être payé à raison de salaire double.5.Tout travail urgent de réparation ou de modification est sujet aux dispositions précédentes, nonobstant toute clause à ce contraire contenue dans le décret.6.L'employeur peut déclarer chômé le lundi suivant ou précédent un jour de fête non religieuse tombant un mardi, un mercredi ou un jeudi, à la place dudit jour de fête, pourvu que salaire double soit payé pour tout travail exécuté le lundi choisi par l'employeur.7.Les dispositions concernant le temps supplémentaire s'appliquent également aux salariés travaillant par équipe, excepté lorsque le chauffage temporaire dans une nouvelle construction exige la présence d'un compagnon ou d'un apprenti.Lorsque des ouvriers sont employés par équipes supplémentaires, il n'y a pas d'heures déterminées pour le commencement et la fin du travail de chaque équipe; la durée du travail des ouvriers qualifiés de telles équipes ne doit pas cependant excéder huit (8) heures par jour et, quarante (40) heures par semaine, du lundi au vendredi.Ces équipes supplémentaires d'ouvriers doivent recevoir un supplément de cinq cents (5c) l'heure sur le salaire régulier.Le travail par équipes est défini comme étant celui d'un ou de plusieurs groupes qui travaillent quatre (4) soirs ou plus de huit (8) heures chacun à la condition qu'une équipe d'ouvriers soient employés sur le même travail durant le jour.e) Travail en dehors des limites de Montréal: Les limites de Montréal, pour les fins du présent article sont les points extrême où l'on peut se rendre avec un billet ordinaire de tramway ou d'autobus de la Commission de Transport de Montréal.Journeyman in plumbing, heating, pipe fitting and pipe welding.2.10 Junior journeyman.1.60 Apprentices: 3rd year.1.20 4th year.1.25 From October 1st 1055, the following readjustments shall be made for the following categories of employees: Journeyman in plumbing, heating, pipe fitting and pipe welding.2.12 Payment of wages: Wages shall be paid to the workers in cash or by certified cheque.c) Duration of work: The maximum duration of work for qualified workers and apprentices shall be eight (8) hours per day distributed between 8.00 a.m.and 5.00 p.m.on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, the whole to constitute a maximum of forty (40) hours per week.d) Overtime: 1.All time worked on New Year's Day, Epiphany, Good Friday, May 24, St.John the Baptist Day, Confederation Day, .Labour Day, Thanksgiving Day, Christmas Day, Immaculate Conception Day, All Saints Day, Ascension Day and Sundays shall be paid double time.2.All time worked on Saturday shall be paid at the rate of time one half for the first four hours of work and at the rate of double time for any additional hours.3.All time worked between 5.00 p.m.and 10.00 p.m.is considered as overtime and paid at the rate of time and one half.4.All time worked between 10.00 p.m.and 8.00 a.m.shall be paid at the rate of double time.5.Urgent alterations and repairs are subject to the above conditions, notwithstanding any clause to the contrary in the decree.6.Employers may declare the following or preceding Monday a holiday in place of any non religious holiday falling on a Tuesday, Wednesday or Thursday, providing double time is paid on any day declared a holiday, if worked.7.Overtime conditions apply to shift workers, except when temporary heat in new buildings requires the attendance of a journeyman or an apprentice.When extra shifts of workmen are employed, there shall be no specified hours of starting and finishing for any shift.They shall not, however, exceed eight (8) hours per day and forty (40) hours per week, Monday to Friday, in the case of qualified tradesmen.Such extra shifts of workmen shall be paid a premium of five cents (5c) above the regular rates.Shift work is defined as that of one or more crews who work four (4) nights or more of eight (8) hours each, providing that a day crew is employed on the same work.e) Operations outside the limite of Montreal: The limits of Montreal, for the purpose of this section, shall be those extreme places that can be reached with an ordinary street car or bus fare of the Montreal Transportations Commissions. 216 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 8 Les salariés travaillant en dehors des limites, telles que ci-haut décrites, doivent se rendre sur le chantier et le quitter aux heures régulières.Le temps requis pour se rendre des limites de la ville au chantier et pour revenir aux limites doit leur être payé au taux simple ainsi que le prix du transport pour ledit trajet.Dans les cas de travaux exécutés en dehors des limites de la cité, on peut varier les heures de commencement et de cessation du travail en vue de les adapter aux heures des services de transport public, pourvu que ne s'ensuive pas une semaine de travail de plus de quarante (\u202210) heures.Les frais de pension et le transport doivent être payés par l'employeur lorsqu'il s'agit de travaux exécutés en dehors des limites de la ville.Les salariés engagés dans la cité de Montréal pour travailler ailleurs doivent être payés d'après les taux spécifiés dans le présent article./) Apprentis: 1.Aucun entrepreneur ne peut embaucher plus d'un apprenti pour chaque compagnon à son emploi, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi des mécaniciens en tuyauterie.2.La période complète d'apprentissage est.de quatre (4) ans, conformément aux dispositions de l'article 12 de la Loi des mécaniciens en tuyauterie.3.Pour pratiquer le métier de mécanicien en tuyauterie, l'apprenti doit avoir un certificat d'apprenti émis par les autorités provinciales, en vertu du chapitre 173 des Statuts refondus de Québec 1941, et conformément au règlement numéro 1341 de la cité de Montréal.Les apprentis non assujettis à la loi des mécaniciens en tuyauterie doivent obtenir le certificat propre à leur métier.g) Vacances payées: L'article XX du présent décret se rapportant aux vacances payées s'applique à la présente section.h) Poseurs de brûleurs à l'huile: Rien dans la présente section n'autorise les poseurs de brûleurs à l'huile à installer des fournaises, des chauffe-eau, etc., ni à effectuer aucune addition, réparation ou extension de tuyau à eau ou à gaz.i) Emploi temporaire: Tout salarié affecté temporairement par le même employeur à un travail autre que celui de son métier doit recevoir le taux de salaire établi pour son métier.j) Travail à la pièce: Tout contrat intervenu entre un employeur et un ou plusieurs salariés pour tout travail exécuté à la pièce, sur une base de contrat ou à prix fixe, est nul et défendu.Le Greffier du Conseil Exécutif, 39063-o L.DÉSILETS.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 20 Québec, le 5 janvier 1955.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant une convention collective de travail relative aux épiciers et bouchers de Sherbrooke.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes ci-après mentionnées ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: Employees working outside the limits, as above described, shall get to, and leave the job, at the regular hours.The time needed to travel from the City limits to the job and vice versa, shall be paid single time.The cost of such transportation shall also be paid by the employer.For operations carried out outside the City limits, it is permissible to change the starting and finishing time in order to adapt same to the time of leaving and returning of public transportation, providing the change docs not entail the working of more than forty (40) hours in one week.Board and travelling expenses shall be paid by the employer in the case of operations carried outside the city limits.Employees hired in the City of Montreal to be employed elsewhere shall be paid the rates specified in this section./) Apprentice: 1.No Contractor shall employ more than one apprentice for each journeyman in his employ, as stated in Section 28 of the Pipe Mechanics Act.2.The entire period of apprenticeship shall be four (4) years, as stated in Section 12 of the Pipe Mechanics Act.3.To ply the pipe mechanic's trade, the apprentice shall obtain an apprentice certificate issued by the provincial authorities pursuant to chapter 173 of the Revised Statutes of Quebec, 1941, and pursuant to by-law number 1341 of the City of Montreal.Apprentices not covered by the Pipe Mechanics Act shall obtain the certificate appertaining to their trade.g) VacatioJi with pay: The entire section XX of the present decree, dealing with vacation with pay, applies to this Part.h) Oil burner mechanics: Nothing contained herein permits an oil burner mechanic to install furnaces, water heaters, etc., nor to make any additions, alterations or extensions to water or gas piping.i) Temporary Employment: Workmen temporarily employed by the same employer at other than their trade work shall continue to be paid the wage rate of their own trade.j) Piece work: All contracts entered into by an employer and one or more employees on a piece work or labour contract basis, or for a fixed price, are invalid and are forbidden.L.DÉSILETS, 39063-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 20 Quebec, January 5, 1955.Present: The Lieutenant Governor in Council.Concerning a collective labour agreement relating to the grocers and butchers of Sherbrooke.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties hereafter mentioned have submitted to the Minister of Labour a petition to render obligatory the collective labour agreement entered into between: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 217 d'une part: L'Association des Marchands Détaillants du Canada-Québec, Inc., section des épiciers-bouchers de Sherbrooke; et, d'autre part: L'Association canadienne des Employés du Commerce, Inc.; pour les employeurs et les salariés des commerces et occupations visés, suivant les conditions décrites dans la Gazette officielle de Québec, édition du 23 octobre 1954; Attendu que les dispositions de ladite convention ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l'établissement des conditions de travail dans les commerces et les occupations visés et dans la juridiction territoriale indiquée dans ladite requête; Attendu que les dispositions de la Loi ont été dûment suivies en ce qui touche la publication des avis; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre ladite requête; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: \u2022 Que ladite requête soit acceptée conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), avec, toutefois, les nouvelles dispositions suivantes tenant lieu des conditions décrites dans la Gazette officielle de Québec, édition du 23 octobre 1954.I.Définitions: Aux fins du décret, les mots et termes suivants ont la signification qui leur est ci-après donnée: a) Employeur: Le terme \"employeur\" désigne toute personne, association ou corporation qui, subordonnément aux paragraphes \"/\" et \"g\" de l'article I de la loi de la Convention collective, tient ou opère un ou des établissements commerciaux ou entreprises privées où l'on fait en détail, en gros et en détail, l'un des commerces assujettis au décret, que ce commerce constitue le commerce principal ou qu'il soit secondaire à tout autre commerce ou occupation.b) Employé: Le terme \"employé\" désigne toute personne salariée de l'un ou de l'autre sexe qui, subordonnément au paragraphe \"j\" de l'article I de la loi de la Convention collective, travaille pour un employeur tel que défini au paragraphe \"a\" du présent article.c) Employé régulier: Le terme \"employé régulier\" désigne tout employé qui fait la semaine régulière de travail de l'établissement où il est employé.d) Employé supplémentaire: Le terme \"employé supplémentaire\" désigne tout employé qui est embauché en plus du personnel régulier, d'une façon intermittente durant la semaine normale de travail.e) Messager: Le terme \"messager\" désigne tout employé qui exécute le travail reconnu comme celui de messager et fait la livraison, soit à pied, soit à bicyclette./) Caissier ou caissière: Le terme \"caissier\" ou \"caissière\" désigne tout employé qui perçoit l'argent venant des ventes et exécute tout autre travail qui est ordinairement fait par le caissier ou la caissière.g) Commis: Le terme \"commis\" désigne tout employé préposé à la perception, à la réception, à l'étalage, à l'étiquetage, au déballage ou à l'emballage, à l'entreposage, à la vente et à l'expédition des marchandises, au débitage, à la préparation et à la vente des viandes.on the one part: The Retail Merchants Association of Canada-Quebec, Inc., \"Section des Épiciers-Bouchers de Sherbrooke\", And, on the other part: \"L'Association canadienne des Employés du Commerce, Inc.\", for the employers and the emploj'ecs of the trades and occupations concerned, according to the conditions described in the Quebec Official Gazette, issue of October 23, 1954; Whereas the provisions of the said agreement have acquired a preponderant significance and importance towards the establishing of working conditions in the trades and occupations concerned and in the territorial jurisdiction indicated in the said petition; Whereas the provisions of the Act have been duly observed as regards the publication of notices; Whereas no objection has been made against the said petition; It \"is ordered, therefore, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said petition be accepted in pursuance of the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments) with, however, the following new provisions to be substituted for the conditions described in the Quebec Official Gazette, issue of October 23, 1954.I.Definitions: For the purpose of the decree, the following terms have the meaning hereinafter given to them : a) Employer: The word \"employer\" means any person, association or corporation who, subordinately to subsections \"/\" and \"g\" of section I of the Collective Agreement Act, keeps or operate one or more commercial establishments or private concerns in which any of the trades governed by the decree is carried on as a retail business or as a wholesale and retail business, whether such trade constitutes the main or secondary trade to all the other trades or occupations.b) Employee: The word \"employee\" means any male or female wage-earning person who, subordinately to subsection \"j\" or section I of the Collective Agreement Act, works for an employer as defined in subsection \"a\" of the present section.c) Regular employee: The words \"regular employee\" mean any employee who works the regular working week of the establishment in which he is employed.d) Extra employee: The words \"extra employee\" mean any employee who is hired over and above the regular staff, intermittently, in the course of the standard work week.e) Messenger: The word \"messenger\" means any employee who performs the work usually known as that of messenger and delivers goods either on foot or with a bicycle./) Cashier: The word \"cashier\" mean any male or female employee who collects the money proceeding from the sales and performs any other work usually carried out by the cashier.g) Clerk: The word \"clerk\" means any employee committed to the sale of goods, to the collection, to the receiving, dispatching, displaying, unpacking, packing, labelling and storing of goods, to the cutting, preparing or selling of meat. 218 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 8 h) Employé de bureau: Le terme \"employé «le bureau\" désigne tout employé qui, faisant le travail clérical de bureau, la correspondance, la tenue des livres, etc., n'est pas autrement désigné dans le décret.i) Livreur: Le terme \"livreur\" désigne tout employé qui, au moyen d'une voiture à traction animale ou d'une voiture-automobile dont il a la charge, l'ait la livraison et le transport des marchandises à tout endroit déterminé par l'employeur.Le livreur, à ses moments libres, doit travailler à l'entretien général de l'établissement.J) Aide-livreur: Le terme \"aide-livreur\" désigne tout employé qui ai.le le livreur à faire la livr.ison et le transport des marchandises.L'aide-livreur, à ses moments libres, doit aider à l'entretien général de l'établissement.k) Apprenti: Le mot \"apprenti\" désigne toute personne «lu sexe masculin ou du sexe féminin ayant moins de six (G) mois d'expérience comme employé «le magasin de détail.II.Juridiction: a) Comm-rciale: Le décret s'applique à toute personne, société, association ou corporation qui exploite un commerce d'épicerie, de boucherie ou «le restaurant-épicerie, dans les limites de la juri liction territoriale ci-après désignée.b) Territoriale: Le décret s'applique à la Cité de Sherbrooke et aux villes de Bromptonville et Lennoxville.III.Heures de travail: a) Les heures de travail de la semaine régulière sont réparties comme suit: Les lundi, mardi, jeudi et samedi: 8.00 a.m.à 6.00p.m.Le mercredi: de 8.00 a.m.a 12.30 p.m.(midi et trente minutes).Le vendredi: de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.b) Toutefois, lorsque dans la semaine, il y a une fête chômée, les heures de travail sont de S.00 a.m.à 6.00 p.m.le mercredi.c) L'employeur doit accorder chaque jour à ses employés une heure pour le repas du midi et de plus, il doit leur accorder une heure pour le repas du soir le vendredi.d) Dans les cas d'urgence où les employés doivent travailler pendant leur période régulière des repas, l'employeur doit leur allouer ce même temps aussitôt que possible dès que l'état d'urgence a cessé et, à tout événement, pas plus tard qu'une heure après la période régulière «les repas.Réserve: Nonobstant les dispositions du décret, la durée des heures de travail dans les établissements commerciaux ne doit en aucun cas constituer une dérogation aux dispositions de la Loi des Établissements Industriels et Commerciaux (Statuts refondus «le Québec 1941, chapitre 175) aux décrets faits sous son autorité et aux règlements établis par les municipalités compétentes.IV.Taux de salaires minima: a) Les taux de salaires minima sont les suivants: Taux a) Classification: hebdomadaire Boucher et acheteur.:.$40.00 Boucher.35.00 Aide-boucher.25.00 Premier commis épicier ou commis en chef 35.00 Commis-livreur.30.00 Autre commis \u2014 homme.25.00 Autre commis \u2014 femme.25.00 Apprenti.20.00 Messager.15.00 b) Les employés doivent être payés toutes les semaines.V.Fêtes chômées et payées: a) Les jours suivants sont des jours de fêtes chômés et payés: h) Office employee: The words \"office employee\" mean any employee who docs office clerk work, correspondence, bookkeeping, etc.and is not otherwise designated in the decree.i) Delivery man: The words \"delivery man\" mean any employee who, with a horse-drawn or motor vehicle of which he is in charge, docs the delivery and transport of goods to any place determined by the employer.The delivery man, in his spare moments, shall work at the general maintenance of the establishment.j) Delivery man's helper: The words \"delivery man's helper\" mean any employee who helps the delivery man in the delivery and transport of goods.The delivery man's helper, in his spare moments, shall help in the general maintenance of the establishment.k) Apprentice: The word \"apprentice\" means any male or female person who has less than six (6) months experience as retail store employee.II.Jurisdiction: a) Commercial: The decree governs any person, partnership, association or corporation operating any grocery, butcher or grocery-restaurant's trade, within the.limits of the territorial jurisdiction hereinafter mentioned: - W b) Territorial: The decree applies to the City of Sherbrooke and the towns of Bromptonville and Lennoxville.III.Working hours: a) The working hours of the standard week shall be distributed as follows: On Monday, Tuesday, Thursday and Saturday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.On Wednesday: 8.00 a.m.to 12.30 p.m.On Friday: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.# b) However, when a holiday falls in a week, the working hours on Wednesday of that week shall be distributed between 8.00 a.m.and 6.00 p.m.c) Employees are entitled, every day, to one hour off for the noon meal and, on Friday, to one hour off for the evening meal.d) When it is urgent that employees work during their regular meal time, the employer shall allow the same lenght of time for lunch (one hour) as soon as possible, and this should not be later than one hour after the regular meal period.Proviso: Notwithstanding the provisions of the decree, the duration of ^working hours in commercial establishments must never constitute a derogation of the provisions of the Industrial and Commercial Establishments'Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 175), of the decrees passed under its authority, nor of the regulations ma«le by competent municipalities IV.Minimum Wage rates: a) The following shall be the minimum wage rates: Weekly a) Classification: Rates Butcher and buyer.$40.00 Butcher.35.00 Butcher's helper.25.00 Chief grocery clerk or chief clerk.35.00 Delivery clerk.30.00 Other clerks \u2014 male.25.00 Other clerks \u2014 female.25.00 Apprentice.20.00 Messenger.15.00 b) Employees shall be paid every week.V.Holidays with pay: a) The following days shall be holidays with pay: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 32nd, 1955, Vol.87, No.3 219 Le Premier de l'An, l'Epiphanie, le Vendredi-Saint, l'Ascension, la fête de la reine Victoria, la St-Jean Baptiste, la Confédération, la fête du Travail, le jour d'Action de Grâces, l'Immaculée Conception, la Toussaint, Noël.b) Si un de ces jours de fête tombe un dimanche, le jour suivant est considéré comme un jour de fête.VI.Vacances payées: a) Tous les employés ayant complété une année de service pour le compte de leur employeur ont droit à six (6) jours de vacances payées: b) Les employés qui ont moins d'un (1) an de service pour leur employeur à la date des vacances ou qui le quitte durant l'année, ont droit à 2% du salaire qu'ils ont gagné.c) Les employés doivent choisir la date de leurs vacances par ordre «l'ancienneté.d) Les salaires pour la période des vacances doivent être payés d'avance aux employés.e) La période donnant droit aux vacances s'étend du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante./) Les vacances doivent être accordées pendant la période s'étendant du 1er mai au 30 octobre de chaque année.g) La date de la semaine de vacances doit être déterminée après entente entre l'employeur et son employé.VII.Uniformes: Si l'employeur exige le port de tabliers ou autres vêtements spéciaux, il doit en assumer le coût et également l'entretien.VIII.Privilèges ou avantages: Aucune «les dispositions du décret ne peut être interprétée de façon à faire perdre aux employés les privilèges ou avantages auxquels, ils ont droit présentement, même s'ils ne sont pas stipulés dans le décret.IX.Durée du décret: Le décret entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec, et demeure en vigueur jusqu'au 30 juin 1955.Il se renouvelle automatiquement, d'année en année, par la suite, à moins que l'une ou l'autre des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit de son intention d'y mettre fin, dans un délai de pas plus de soixante (60) jours ni de moins de trente (30) jours avant l'expiration du terme original ou de toute année subséquente.Un tel avis doit également être adressé au ministre du Travail.L.DÉSILETS, 39063-o Greffier du Conseil Exécutif.New Year's Day, Epiphany, Good Friday, Ascension Day, Victoria Day, St.John the Baptist Day, Confederation Day, Labour Day, Thanksgiving Day, Immaculate Conception Day, All Saints Day, Christmas Day.b) If one of the above menti->ne I holidays fall on Sunday, the following day shall be observed as a holiday.VI.Vacation with pay: a) All employees with one year of service for their empl- yer are entitled to six (6) days of vacation with pay.b) Employees with less than one (1) year of service for their employer at the date of vacation, or those of leave their employer during the year arc entitled to 2% of the wages earned in the service of such employer.c) Employees shall choose the date of their week's vacation by order of seniority.d) The wages for the vacation period shall be paid in advance to the employees.c) The period entitling the employee to such vacation extends from May 1st of one year to April 30th of the next year./).Vacations must be given du-ii'g the period extending May 1st to October 3fth of each year./) Vacations must be given during the period g) The date of vacation shall be determined by mutual agreement between employers and employees.VII.Uniforms: If the employer requires his employees to wear aprons or any special uniform, he shall pay the cost and maintenance thereof.VIII.Privileges and advatanges: No provision of the decree shall be so interpreted as to cause the employees to lose the privileges or advantages to which they are now entitled, even if such privileges or advantages are not stipulated in the decree.IX.Duration of the Decree: The decree comes into force on the day of its publication in the Quebec Official Gazette and remains effective until June 30th, 1955.II then renews itself automatically from year to year unless one of the contracting parties notifies the other party, in writing, to the contrary within the period extending from the 60th to the 30th day before the expiration of the original term or of any subsequent year.Such a notice shall also be given to the Minister of Labour.L.DÉSILETS, 39063-o Clerk of the Executive Council.Ventes pour taxes Sales for Taxes Province de Québec Province of Quebec Municipalité du comté de Drummond Municiaplity of the county of Drummond Avis public est par les présentes donné par Public notice is hereby given by the under- le soussigné, Marcel Marier, secrétaire-trésorier signed, Marcel Marier, secretary-treasurer of du Conseil de cette municipalité, que les terrains the above municipality, that the lands hereinaf- ci-dessous mentionnés seront vendus à l'enchère ter described will be sold by public auction, in publique dans le Palais de Justice, à Drummond- the Court House, at Drummondvillc, in the ville, dans ladite municipalité, étant le lieu où said Municipality, being the place where the se tiennent les sessions du Conseil de cette mu- said municipality holds its sessions, THURS- nicipàlité, JEUDI, le DIXIÈME (10) jour de DAY, the TENTH (10) day of MARCH next, MARS prochain (1955), à DIX (10) heures de (1955), at the hour of TEN (10) o'leock in the l'avant-midi, à défaut du paiement des taxes forenoon, in default of payment of the taxes auxquelles ils sont affectés, et les frais encourus, for which they are liable and the costs incurred, savoir: to wit: , 220 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1956, Tome 87, N° 8 Dans la municipalité de Grantham-Oucst \u2014 In the municipality of Grantham-West Nom du propriétaire\tN° du cadastre\tRang\tTaxes munie.\tTaxes scol.\tTotal Name of owner\tCadastral No.\tRange\tMunie, taxes\tSchool taxes\t \t\t\t$16.10\t$26.50\t$42.60 Les subdivisions partie trente-dinq, trente-six, Subdivision parts thirty-five, thirty-six, thirty-se- trente-sept et trente-huit du lot numéro de cadastre ven and thirty-eight of lot bearing cadastral number cent vingt-quatre du canton de Grantham: 124- (P.one hundred and twenty-four of the township of 35, 36, 37, 38) Grantham.Grantham; 124 (P.35, 36, 37, 38) Grantham.Parker, Walter.|.I.| 49.02 I 137.00 | 186.02 La subdivision deux cent soixante-quatorze et la Subdivision two hundred and seventy-four and half of moitié de la subdivision deux cent soixante-quinze du subdivision two hundred and seventy-five of lot bearing lot numéro de cadastre cent soixante-douze du cadastre cadastral number one hundred and seventy-two of the du canton de Grantham, avec bâtisses y érigées; cadastre of the township of Grantham, with buildings (172-274, y2 172-275, Grantham).erected thereon; (172-274, 172-275, Grantham.) Dans la municipalité du village de Wickham-Ouest In the municipality of the village of Wickham-West Cormier, Aristide.|.I.| $92.60 |$124.90 | $217.50 Les lots quatre cent soixante-dix-sept et quatre Lots four hundred and seventy-seven and four cent soixante-dix-neuf, du canton de Wickham; rang 9, hundred and seventy-nine, township of Wickham; village de Wickham-Ouest, (477, 479, canton do range 9, village of Wickham-West, (477, 479, township Wickham).of Wickham).Dans la municipalité de St-Félix de Kingsoy \u2014 In the municipality of St.Felix de Kingsey Lussier, Gérard.|.I.| $42.89 | $18.22 | $61.61 Partie lot lid, rang 5, 1/32 acre; du canton do Part of lot lid, range 5, 1/32 acre; township of Kingsey.Kingsey.(Bureau des commissaires d'écoles Protestantes) (Board of Protestant School Commissioners) \tLot 1-B.\t1.\t\t$691.11\t$691.11 \tLot 2-B.\t1\t\t\t \tLot 6-B.\t2\t\t\t \tP.18 et-and P.19.\t3.\t\t\t \tdu canton do Kingsey-of township of Kingsey.\t\t\t\t Dans la municipalité de L'Avenir \u2014 In the municipality of L'Avenir Bolduc, Ronald et-and Bouchard, M.|.|.| $83.50 | $80.40 | $163.90 Les lots numéros six cent vingt-deux et six cent Lots number six hundred and twenty-two and six vingt-trois ud cadastre du canton do Durham; (622, hundred and twenty-three of tho cadastre of Durham 623, Durham).Township; (622, 623, Durham).Dans la municipalité do St-Majorique \u2014 In the municipality of St.Majorique Martel, Lucien.|.I.| $57.72 | $52.03 I $109.75 Lot partie soixante-sept et soixante-huit; 1er rang, Lot part sixty-seven and sixty-eight; range 1, St St-Majorique, du cadastre du canton de Grantham; Majorique, cadastre of township of Grantham; bounded borné au nord par la rivière St-François, au sud par le northerly by River Saint Francis, southerly by range 2 chemin du 2e rang, à l'est par la propriété de la Sou- road, easterly by the property of the Southern Canada them Canada Power Co.Limited, à l'ouest par la Power Co.Limited, westerly by tho property of propriété de Joseph Ruel; partie 68, superficie 194 Joseph Ruel; part 68, area: 194 acres, acres.\u2022 \u2022 Martel, Lucien.).I.I $92.39 |$116.43 | $208.82 Lot numéro soixante-neuf, 2e rang, St-Majorique; Lot number sixty-nine, range 2, St.Majorique; du cadastre du canton de Grantham; borné au nord par cadastre of township of Grantham; bounded northerly le chemin du 2e rang, au sud par le chemin du 3e rang, by range 2 road, southerly by range 3 road, easterly à l'est par le lot partie 70 propriété do Alphée Joyal, by lot part 70, property of Alphée Joyal, westerly by à l'ouest par la ligne de division des municipalités de the dividing line between the municipalities of St.Bo- St-Bonaventuro et St-Majorique; superficie do la haventure and St.Majorique; area of the property, propriété 200 acres.\" 200 acres.Dans la municipalité de St-Lucien \u2014 In the municipality of St.Lucien Desmarais, David.1.1.1 $30.72 I $ 11.28 I $42.00 * Un-quart nord-ouest du lot numéro dix-sept, 4o rang, A northwesterly quarter of lot number seventeen.Simpson; (M N.O.17 Simpson.) borné au nord- range 4, Simpson; (J4 N.W.17, Simpson.) bounded ouest par le lot numéro seize.northwesterly by lot number sixteen. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 221 Dans la municipalité de St-Simon do Drummond \u2014 In the municipality of St.Simon de Drummond Nom du propriétaire Name of owner N° du cadastre Cadastral No.Rang Range Taxes munie.Munie, taxes\t\tTaxes scol.School taxes\t\tTotal $ 8\t75\t813.28\t\tS 22.03 83\t64\t17\t38\t101.02 13\t44\t19\t77\t33.21 29\t21\t41\t12\t70.33 1\t88\t3\t15\t5.03 11\t05\t\t\t11.05 1,053\t81\t318\t67\t1,372.48 30\t09\t60\t43\t99.52 15\t03\t23\t53\t38.56 4\t26\t6\t59\t10.85 5\t63\t9\t18\t14.81 11\t00\t17\t38\t28.38 535\t84\t336\t16\t872.00 5\t60\t7\t18\t12.78 226\t85\t205\t98\t432.83 Raid, Marcel.Blanchctte, Jean-Denis Cournoycr, Joseph Croteau, Herman.Inconnu-Unknown Johnson, D.Lcvcsque, Henoch.Menard, Gérard.Mercure, Grégoire.Pinard, Albert.Parisien, Rolland.Plante, Rolland.Ratté, J.Aurélien- Vachon, Emile.Vézina, Jean-Paul.139-473 du-of canton de-township of Grantham.103-102 du-of canton de-township of Grantham.102-152 du-of canton de-township of Grantham.102 (157, 191, 200) du-of canton de-township of Grantham.Partic-part 106, du-of canton de-township of Grantham.107-52 du-of canton de-township of Grantham.103(100, 153, 154,155, 156) du-ofcanton de-of Grantham.Partie-part 106, du-of canton de-township of Grantham.105-72, du-of canton de-township of Grantham.106-35, du-of canton de-township of Grantham.139-927, du-of canton de-township o Grantham.107-28, du-of canton de-township of Grantham.138 (P.66, 67) du-of canton de-townshii of Grantham.139-492, du-of canton de-township o Grantham.138 (217, 216, P.) du-of canton de-town ship of Grantham Dans la municipalité du village de St-Cyrille \u2014 In the municipality of the village of St.Cyrille Marineau, Donat et-and Marineau Succ.-.Est.Dame Donat.Un terrain, mesurant' cinquante pieds de front sur cent pieds do profondeur, connu et désigné au plan et livre de renvoi officiel du cadastre dy comté de Drummond, pour le canton do Simpson, comme étant uno partie du lot numéro un B (P.1-B) dans le 4e rang, borné au front au nord-ouest la route Nationale, en profondeur au sud-est Emile Lcmaire, d'un côté au nord-est Joseph Ruel et do l'autre côté au sud-ouest Germain Proulx.$ 4.47 8 5.53 $ 10.00 A piece of land measuring fifty feet in frontage by one hundred feet in depth, known and designated on tho official plan and book of reference of the cadastre of the county of Drummond, for tho township of Simpson, as being a part of lot number one B (P.1-B) in range 4, bounded in front, northwesterly by the National highway, in depth, southeasterly, by Emile Leinire, on the northeast side by Joseph Ruel and on the other side, southwesterly by Germain Proulx.Drummondville, ce 11 janvier 1955.Le Secrétaire-trésorier du Conseil (Sceau) de Comté de Drummond, 39080-3-2-o MARCEL MARIER.Province de Québec Municipalité du comté de l'Islet Le soussigné donne avis à tous intéressés qu'il vendra les- immeubles ci-après désignés, à l'enchère publique, en la salle municipale de St-Jean-Port-Joli, JEUDI, le DIX MARS 1955, à DIX heures du matin, faute de payement des taxes auxquelles ces immeubles sont assujettis et des frais encourus.Drummondville, this January 11, 1955.(Seal) MARCEL MARIER, Secretary-Treasurer of the Council 39080-3-2-o of the county of Drummond.Province of Quebec Municipality of tiie county of L'Islet Notice is hereby given to all interested parties that the undersigned will well the immoveables hereunder described, by public auction, in the Municipal Hall of St.Jean Port Joli, on THURSDAY, the TENTH day of MARCH, 1955, at TEN o'clock in the forenoon, for the non-payement of taxes due on the said immoveables with costs incurred thereon.v Municipalité de Saint-Omer \u2014 Municipality of Saint Omer \t\tTaxes\tTaxes\t Noms\tN° du cadastre\tmunie.\tscol.\t \t\u2014\t\u2014\t\u2014\tTotal Names\tCadastral No.\tMunie.\tSchool\t \t\ttaxes\ttaxes\t \t\ts 4.45\t$43.50 49.60\t$47.95 49.60 \t\t\t\t 222 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 Municipalité do Saint-Omer \u2014 Municipality of Saint Orner \t\tTaxes\tTaxes\t Noms\tN° du cadastre\tmunie.\tscol.\t \u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\tTotal Naines\tCadastral No.\tMunie.\tSchool\t \t\ttaxes\ttaxes\t \t\t5.00 7.00 5.50 0.00 6.00 4.50 3.60\t16.00 59.35 30.70 37.90 29.75 43.50\t21.00 66.35 36.20 43.90 35.75 48.00 3.60 \t\t\t\t \t40, rang-range 3, Dionno .\t\t\t \t2i), rang-rango 1, Dionne.\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Municipalité de Saint-Marcel \u2014 Municipality of Saint Marcel Gérard Talbot.Simon Pelletier Anthyme Morin Maurice Lord.Claude Dubé.Mme-Mrs Aimée Pelletier.Léonard Bcrnier.Mme-Mrs Simone Pelletier.39, rang-range 6, Arago.15, rang-range 5, Arago.P.42 rang-range 1, Arago, 25 acres P.26 rang-range 5, Arago, 14 nerc P.27, rang-range 6, Arago 95 acres P.28, rang-range 6, Arago 1 }4 ac.P.nord 34, rang-range 5, Arago 66 acres.P.13, rang-range 2, Arago, H ac.P.35, rang-range 5, Arago ac.P.35, rang-range 5, Arago, 49H ac 52, rang-range 4, Arago.P.32, rang-range 6, Arago, 14 acres nord-est\u2014north-east.35.79 30.89 4.02 9.49 30.47 31.88 12.46 4.93 1.10 11.35 18.37 11.28 35.79 30.89 4.02 9.49 30.47 31.88 12.46 4.93 1.10 11.35 18.37 11.28 Municipalité de Tourvillo \u2014 Municipality of Tourvillo Inconnu-unknown.19, rang-range 11, Ashford 13.21 13.21 Municipalité de Sainte-Lucie do Beauregard \u2014 Municipality of Sainte Lucie de Beauregard Lauréat Bélanger .Gérard Caron.Arthur Roycr.M.-Antoine Blanchet 1, rang-range 3, Leverrier .9, rang-range 3, Leverrier .10, rang range 3, Leverrier 1, rang-range 4, Leverrier .27.00 20.80 50.88 28.05 27.00 20.80 50.88 28.05 Municipalité de Saint-Aubert \u2014 Municipality of Saint Aubcrt Henri Daigle.I P.76, St-Aubert .'.| 7.27 |.| 7.27 Ayant )4 d'arpent de superficie, bornée à l'est par le \\i of an arpent in area, bounded to the east by lot lot 75 et à l'ouest par le lot 77.75 and' to the west by lot 77.Jos.-Edmond Leclerc Julien Saint Pierre .218, 221, 223 182.23.84 24.34 23.84 24.34 Municipalité de Saint-Adalbert \u2014 Municipality of Saint Adalbert Edouard Pelletier 24, rang-range 6, Leverrier 4.10 4.10 Municipalité de Saint-Cyrille \u2014 Municipality of Saint Cyrille Amédée Houle.| P.105, rang-range 1 St-Cyrillo-1.| 1.00 | 1.00 Mesurant environ 8 arpents de supreficie, bornée au Measuring about 8 arpents in area, bounded to the nord au fronteau, au sud a la rivière, à l'est à Antonin north by tftë range line, to the south by the river, to Bernier, à l'ouest à Michel Gagnon.the east by Antonin Bernier, to the west by Michel Gagnon.J.-Zéphirin Coulombe.| P.199, rang-range 2, St-Cyrille .| 8.85 | 12.96 | 21.81 Mesurant 3 arpents de superfice, bornée au nord par Measuring 3 arpents in area, bounded to the north le chemin public, au sud et à l'ouest par Thomas Thi- by the highway, to the south & the west by Thomas bault, à l'est par Cyrille Fortin.Thibault, to the oast by Cyrille Fortin.Municipalité de Sainte-Louise \u2014 Municipality of Sainte Louise Patrice Morneau.Mme-Mrs Alfred Richard Victorin Pelletier.Adélard Gagnon.Orner Harton .Arsène Castonguay.André Pelletier.8, 9, 221, 229.137, 141, 144, 355, 358.167, 411,505.397, 398, 399, 402.P.1 p.4, p.230 .P.439 (St-Roch-des-Aulnaies), P.244 (Ste-Louise).109.70.31\t153.86\t224.17 31.99\t125.41\t157.40 42.65\t15.68\t58.32 11.49\t\t11.49 22.22\t127.20\t149.42 6.03\t35.79\t41.82 \t8.10\t8.10 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.8 223 Municipalité du canton Ashford \u2014 Municipality of Township Ashford \t\tTaxes\tTaxes\t Noms\tN° du cadastre\tmunie.\tscol.\t \u2014\t\u2014\t\u2014\t_\tTotal Names\tCadastral No.\tMunie.\tSchool\t \t\ttaxes\ttaxes\t \tP.21C, rang-rangc 3, Fournier.\t3.38\t4.25\t7.63 De }4 arpent de front sur la profondeur qu'il y a, Of 14 arpent in front by the existing depth, bounded tenant nord à la Traverse du Detour, sud au chemin to the north by \"Traverse du Détour\", south by Price's des Price, est à Euclide Chouinard, sud-ouest à Maxime road, cast by Euclide Chouinard, South-west by Maxi- Saint-Pierre.me Saint-Pierre.Alfred Caron.| P.426, St-Aubert.| 8.79 [ 12.30 | 21.00 D'un arpent de largeur et un arpent et demi do Of an arpent in width and an arpent and one half in profondeur, tenant sud-est a la route, nord-est à Joseph depth, bounded to south-east by the highway, north-Desrosiers, nord-ouest à Albert Desrosicrs, sud-ouost east by Joseph Desrosicrs, north-west by Albert Des-à Orner Desrosicrs.rosiers, south-west by Orner Desrosiers.Emmanuel Castonguay.P.102, 103, 104, 105, 106, 107 et 1 108, rang-range 1 d'Ashford- 3.26 23.00 26.26 Contenant la largeur do ces lots sur la profondeur qui Containing tho width of said lots by the depth there\" s'y trouve, tenant nord-ouest il Arthur Bélanger et in, bounded to the north-west by Arthur Bélanger and au fronteau du rang, au sud-est à un ruisseau.the range's frontage, south-cast by a brook.St-Jean-Port-Joli, 8 janvier 1955.Le Secrétaire-trésorier de la municipalité du comté de L'Islet, 39081-3-2-o E.M.DÉCHÊNE.Province de Québec Municipalité du comté de Papineau Avis public est, par les présentes, donné par le soussigné Albert Boulais, Secrétaire-trésorier du Conseil municipal du comté de Papineau que les propriétés suivantes seront vendues à l'enchère publique, en l'Hôtel de ville du village de Papincauviitc, lieu ou le Conseil de Comté tient ses sessions, JEUDI, le DIX MAPS, mil neuf cent cinquante-cinq (1955), à DIX heures de l'avant-midi pour les taxes municipales et scolaires et autres charges dues aux Municipalités ci-après énumérées, sur les divers lots de terre ci-après désignés, à moins qu'elles ne soient payées avec les frais avant la vente.St-Jean-Port-Joli, January, 8th, 1955.E.M.DÉCHÊNE, Secretary-Treasurer of the Municipality of 39081-3-2-o the county of L'Islet.Province of Quebec -Municipality ok the county of Papineau Public notice is hereby given, by the undersigned Albert Boulais, Secretary-Treasurer of the Municipal Council of the county of Papineau, that the lots of lands hereinafter described will be sold, by Public Auction, in the Town Hall of the village of Papineàuville, place where the sessions of the Countv Council are held, on THURSDAY, the TENTH of MARCH, one thousand nine hundred and fifty-five (1955), at TEN o'clock in the forenoon, for the municipal and school taxes and other charges diie to the hereinafter mentioned Municipalities, on the lots of lands hereainfter described, unless the same be paid with the costs, before the sale.Municipalité du canton d'Amherst \u2014 Municipality of tho township of Amherst Canton-Township \u2014 Lots \u2014 Superficies\tRang Range\tTaxes\tPropriétaires Owner Canton-Township Amherst, 17.P.18A.P.O.3-43, 3-44, 3-45, 3-47, 3-48, 3-49.3-50.P.S.24C, P.25A.12A, I2B, P.11.P.0.6B.\tA B 5N B 5S 5N\tS 18.32 145.09 311.70' 149.30 2.99\tAldège Richard.Paul-Emile Roy.Edouard Thomas.Edouard Thomas.Mme-Mrs Armand Chevalier.Municipalité du village de Papineàuville \u2014 Municipality of the village of Papineàuville\t\t\t Paroisse-Parish Ste-Angeliquc, 102, P.103.\t\t109.80\tMme-Mrs Joseph Larocquc & Eu-chariste Giroux.é Municipalité de Ste-Angélique \u2014 Municipality of Ste-Angéliquc\t\t\t \t\t88.85\tRosario Brazeau. 224 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 Municipalité do Villeneuve \u2014 Municipality of Villenouvo \tRang\t\tPropriétaires Canton-Township \u2014 Lots \u2014 Superficies\t\u2014\tTaxes\t\u2014 \tRange\t\tOwner \t3\t96.98\tAntoine Pichette.Municipalité scolaire N.-D.do la Salette \u2014\tSchool Municipality of N.-D.do la Salette\t\t Portland-Est-East, P.4.\t6\t40.05\tSylvio Boisvenu.Portland-Est-East, P.5B.\t6\t23.00\tJean Noël Hart.Municipalité du canton do Ripon \u2014 Municipality of the township of Ripon Canton-Township Ripon, 51B, 52, P.O., 51A.\" 51C, 51D.\" 52B, P.53B, P.54B, P.55B, 56A, 57A.\" P.51A.3\t$119.36 4\t11.35 4\t128.28 4\t77.33 C.O.Bousquet.C.O.Bousquet.C.O.Bousquet.Mme-Mrs Loretta Harrigan.Municipalité scolaire de Ripon \u2014 School municipality of Ripon \t7\t22.80\tCollin Kemp.Municipalité de Cheneville \u2014 Municipality of Cheneville\t\t\t Canton-Township Hartwell, P.11A 1/8 arp.P.11A.P.11A 1/8 arp.P.12A K arp.\t1 2 2 2\t$46.75 180.52 44.05 96.54\tTélesphore Servant.Alcide Hotte.Maximilien Dinel.Emile Saliba.* Municipalité do Hartwell \u2014 Municipality of Hartwell Canton-Township Hartwell, P.37-1.i.P.31.P.23.44,45,46.P.14A.\t4 2 4 1 4\t6.41 6.35 51.90 12.30 30.07\tEmile Savaria.Joseph Saliba.J.Paul Spronken.J.Paul Spronken.Maximilien Dinel.Municipalité scolaire Hartwell -\t\u2014 School municipality Hartwell\t\t \t7'\t9.68\t \" P.9, 1 arp.P.32.P.29.P.23.P.24B.\t7 4 4 2 2\t7.43 23.15 29.60 42.70 23.56\tRosaire Pilon.Gertrude Cameron.v Mme-Mrs Rita Lavoie Lamer.Théo.Hanna.H.D.Partridge.Municipalité de Duhamel -\t- Municiaplity of Duhamel\t\t Canton-Township Preston, P.21C.P.E.24.\t2 3 1\t26.42 3.35 48.48\tHilaire Filion.Hilaire Filion.Henri St-Jean.Municipalité de Lochaber-Ouest -*\t\u2014 Municipality of Lochaber-West\t\t V O.-W.12 & K E.13.\t\t72.95\t 15 Milton.\t88.81 93.42\t\t161.76 153.42 20.48 50.04 10.91 220.54 \t\t00.00 20.48 50.04 7.51 55.19\t 12C.\t\t\t \t\t\t 028-327.010-10, P.sud-south.\t3.40 105.35\t\t Forand, Albert.(Emile Dclorme) Gélineau, Aldci.Hardy, Paul-Émilc (David Hoy).Lavallée, Fernand (Winifred Purely) Picard René (Hennas Picard).Picard, Wellio (Hannas Picard) .Picard, Roger.Roy, Georges.Fontaine, Roméo Langlois, Justinicn .Bédard, Jos.Durcnleau, Théophile.Canton de Shefford \u2014 Township of Shefford Trudeau, Adrien.P.481.35.61 14.30 49.91 Delisle, Arthur.\u201e.\u2022.739-740.19.76 16.37 36.30 Succ.-Estate Wallace, L.D.:.721-723.6.90 .6.90 Succ.-Est.Hayes, Jas.1297-1295 P.279.93 105.80 445.73 Stukely, Partie Est \u2014 Stukely, East Part \t960, 1044 .s.\t98.01\t\t98.61 161.33 \t\t\t161.33\t \t\t\t\t Village de Stukely-Sud \u2014 South-Stukcly (village)\t\t\t\t \t12.\t30.05\t\t30.05 \t\t\t\t Stukely-Sud (Paroisse) \u2014 Studely-South (Parish)\t\t\t\t \t\t30.75 51.97 61.98 11.93\t\t30.75 51.97 01.98 11.93 \t348.\t\t\t \t206-207.\t\t\t McKenna, Thomas.\tP.132.\t\t\t Donné à Waterloo, ce 14 janvier 1955.Given at Waterloo this 14th, January, 1955.(Sceau) (Seal) Le Secrétaire-trésorier, C.H.LEFEBVRE, du comté de Shefford, Secretary-Treasurer, 39097-3-2-o C.H.LEFEBVRE.39097-3-2-q County of Shefford.Province de Québec Municipalité du comté de Portneuf Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Alfred Naud, secrétaire-trésorier du conseil municipal du comté de Portneuf, que Province of Quebec Municipality of the county of Portneuf Public notice is hereby given by the undersigned, Alfred Naud, secretary-treasurer of the municipal countil for the county of Portneuf, that, 240 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 8 JEUDI, lo DIXIÈME jour du mois de MARS mil neuf cent cinquante-cinq, à DIX heures de l'avant-midi, à Cap-Santé, à la salle d'audience du conseil, les terrains ci-après décrits seront vendus pour taxes municipales et scolaires et charges auxquelles ils seront affectés, à moins qu'elles ne soient payées, avec les frais, savoir: Municipalité du Montauban-les-Mines Comme appartenant à \"Propriétaire inconnu\", une partie du lot N° 39 du 1er rang Montauban; 1/8 d'arpent; bornée au nord et à l'est par la coulée des téling's, à l'ouest par Cyrille Audy et au sud par le chemin public.Taxes ducs: $10.72.Comme \"appartenant à J.A.Nault, une partie du lot N° 39 du 1er rang Montauban.1/8 d'arpent; bornée au nord par Honorât Rompre, à l'est et au sud par J.-Paul Garncau et à l'ouest par Oscar Champagne.Taxes ducs: 87.82.Municipalité de St-Raymond paroisse Comme appartenant à Joseph N.Godin, parties des lots Nos 541 et 542 du cadastre officiel du comté de Portneuf, pour la paroisse de St-Raymond, décrites dans un acte enregistré sous le N° 88825.Taxes dues: $74.20.Comme appartenant à Hervé Marcotte, parties des lots Nos 748 et 760 du cadastre officiel du comté de Portneuf, pour la paroisse de St-Raymond, décrites dans un acte enregistré sous le N° 122389.Taxes dues: $15.22.Municipalité de Grondines paroisse Comme appartenant à Arthur Naud, parties des lots Nos.453 et 454 du cadastre officiel du comté de Portneuf, pour la paroisse des Grondines, décrites dans un acte enregistré sous le N° 132653.Taxes dues: $53.78.Comme appartenant à Jimmy Welsh, une partie du lot N° 471 du cadastre officiel du comté de Portneuf, pour la paroisse des Grondines, décrite dans un acte enregistré sous le N° 132578.Taxes dues: $4.23.Comme appartenant à Maurice Paquin ou Henri Marcotte, une partie du lot N° 453 du cadastre officiel du comté de Portneuf, par la paroisse des Grondines, décrite dans des actes enregistrés sous les Nos 121438 et 131704.Taxes dues: $8.10.Comme appartenant à la Corporation municipale de Grondines paroisse, ou à Edouard Laga-nière, le lot N° 449 du cadastre officiel du comté de Portneuf, pour la paroisse des Grondines.Taxes dues: $4.05.Municipalité de Pont-Rouge Comme appartenant à la Succession de Armand Defoy, le lot N° 101-3 et une partie du lot N° 98 du cadastre officiel du comté de Portneuf, pour la paroisse de Ste-Jeanne de Neuville.Taxes dues: $127.94.Donné à Deschambault, le cinquième jour du mois de janvier, mil neuf cent cinquante-cinq.Le Secrétaire-trésorier, 39096-3-2-o ALFRED NAUD.THURSDAY, the TENTH day of the month of MARCH one thousand nine hundred and fifty-five, at TEN o'clock in the forenoon, at Cap Santé, in the sitting room of the council, the lands hereinafter described will be sold by auction for the municipal and school taxes and other charges to which they will be liable, unless the same be paid, with costs, to wit; Municipality of Montauhan-les-Mines As belonging to \"Unknown owner\", a part of the lot No.39 in the first range Montauban, 1/8 of an arpent; bounded to the north and to the east by the coulée of the télings, to the west by Cyrille Audy and to the south by the public road.Taxes due: $10.72.As belonging to J.-A.Nault, a part of the lot No.39 in the first Montauban, 1/8 of an arpent; bounded to the north by Honorât Rompre, to the east and to the south by J.-Paul Garncau and to the west by Oscar Champagne.Taxes due: $7.82.Municipality of the parish of ,St-Raymond As belonging to Joseph N.Godin, parts of the lots Nos 541 and 542 of the official cadastre of the county of Portneuf, for the parish of St-Raymond, described in a deed registered under No.88825.Taxes due: $74.20.As belonging to Hervé Marcotte, parts of the lots Nos.748 and 760 of the official cadastre of the county of Portneuf, for the parish of St-Raymond,- described in a deed registered under No.122389.Taxes due: $15.22.Municipality of the parish of Grondines As belonging to Arthur Naud, parts of the lots Nos.453 and 454 of the official cadastre of the county of Portneuf, for the parish of Grondines, described in a deed registered under No.132653.Taxes due: $53.78.As belonging to Jimmy Welsh, a part of the lot No.471 of the official cadastre of the county of Portneuf, for the parish of Grondines, described in a deed registered under No.132578.Taxes due: $4.23.As belonging to Maurice Paquin or Henri Marcotte, a part of the lot No.453 of the official cadastre of the county of Portneuf, for the parish of Grondines, desceibed in deeds registered under Nos 121438 and 131704.Taxes due: $8.10.As belonging to the municipal corporation of the parish of Grondines or to Edouard Laganière, the lot No.449 of the official cadastre of the county of Portneuf, for the parish of Grondines.Taxes due: $4.05.Municipality of Pont-Rouge As belonging to the heirs of Armand Defoy, the lot No.101-3 and a part of the lot No.98 of the official cadastre of the county of Portneuf, for the parish of Ste-Jeanne de Neuville.Taxes due: $127.94.Given at Deschambault, the fifth day of the month of January one thousand nine hundred and fifty-five.ALFRED NAUD, 39096-3-2-o Secretary-Treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 241 Province de Québec District de Terrebonne Municipalité du comté des Deux Montagnes Avis public est par les présentes donné par le soussigné J.Léo.Bcaudet, secrétaire trésorier de la Corporation du comté des Deux-Montagnes que JEUDI, le DIXIÈME jour de MARS mil neuf cent cinquante-cinq à DIX heures de l'avant-midi en la salle municipale du comté des Deux-Montagnes à Ste-Scholastique, les immeubles suivants seront vendus à l'enchère publique pour taxes municipales et scolaires ducs sur chacun de ces immeubles à moins que ces taxes ne soient acquittées avec les frais encourus avant la vente savoir: Province of Quebec District of Terrebonne Municipality of the county of Two Mountains Public notice is hereby given by the undersigned J.Léo.Beaudet, secretary-treasurer of the Corporation of the county of Two Mountains, that THURSDAY the TEENTH of MARCH nineteen hundred and fifty five at TEN o'clock in the forenoon in the Hall of the county at Ste-Scholastique the following immoveable property will be sold at public auction for municipal and school taxes due on each of the same lots unless those taxes together with the cost incurred up be paid before the sale to wit: Paroisse de St-Bcnott \u2014 Parish of St-Benott Norn\tAdresse\tN° du lot et du cadastro\tMontant du Name\tAddress\tLot and cadastral No.\tAmount due \tSte-Scholastique, R.R.No 1.\t190 i\\-to 195, 198.\tS 211.10 \t\t\t Village de St-Eustache sur le Lac \u2014 Village of St-Eustachc on the Lake Dowling, G.A.Germain, Juliette, épouse de wife of H.Germain.Laramée, Mme-Mrs Victor veuve-widow.Miller, Lucien, vendeur-sales- man.Marry, Catherine, fille majeu-re-spinster.McCarthy, Mme-Mrs P.épouse de-wife of P.McCarthy.Urbaitis, Jonas.3567 Beaubien-E., Montréal.405, 5ième avenue, St-Eustacho sur le Lac.67, llième avenue St-Eustache sur le Lac.8172 Lajeunesse, Montréal.294 Channon, Montréal.783 3ième avenue, Verdun.611 Belmont st., Montréal.t.80/17.67/104-105.60/220.77/177-178.97/71-72-73-74 88/128-129.80/11.Municipalité de la partie nord de la paroisse de l'Annonciation d'Oka Municipality of the north part of the parish of l'Annonciation of Oka Lalonde, J.-Aimé.Brisobois, France.Belisle, Maurice.Cat a i ill mil, Hector.Poulot, Henri.Hôtel Mt.St-Pierre St-Eustache sur le Lac.Oka.352 de Castelneau, Montréal Oka.9400 Berri Ap.4, Montréal.La Trappe.224.P.226____ 17-275 P.17.17-268-267 P.176____ Municipalité d'Oka \u2014 Municipality of Oka Amyet, Aimé.'.Boileau, Ephraim.Cameron, Mme-Mrs J.M.Chené, Jacques.DelVecchio, M.Desjardins, Alcide.Doutte, René.Gagnier Félicien.Jacobsen, L.Pelletier, Mme-Mrs R.Proulx & Lauzon.Tabah, E.N.Trottier, Albert.Turcot, Rosaire.323 Wiseman, Montréal.Oka.2327 Wilson, N.D.C.Oka.294, Car.-W.St-Louis, Montréal Oka.Oka.Oka.Oka.181 J.Verne Mtl.St-Jos.du Lac, 3261 Blé.Perron Montréal.Oka.Oka.19 & 20.195-54____ 18-2.P.195____ 147-91____ 60-1-2-59-2 P.17.79.P.29.87.P.17.55.17-47.78 17-16.Municipalité de St-Colomban \u2014 Municipality of St-Colomban Succ.-Est.A.Boissonncault.Succ.-Est.A.Rochon.Holding, Chelsea.Pat, Murphy.Jos.E.St.Jean.Neil, Gumis.Neil, Gumis.Succ-Est.J.Holland.Succ.-Est.abbé Martel.39 St-Jacques E.St-Canut.Lachute, R.R.No.6 Now Glasgow.Ste-Scholastique.St-Colomban.St-Colomban.Inconnue-unknown.Inconnue-unknown.P.21.P.23.108-109____ 110-111-112 130-131-132 P.191.P.158-159.P.317.319-320. 242 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 Paroisse de St-Canut \u2014 Parish of St-Canut Nom\tAdresse\tN° du lot et du cadastre\tMontant du \u2014\tAddress\tLot and cadastral No.\tAmount due \t507G, Bréboeuf, Montreal.\tP.92.\t55.37 Avec les bâtisses y érigées s'il y a lieu.With the buildings thereon erected if there is any.Donné à Stc-Scholastiquc ce onzième jour de janvier mil neuf cent cinquante-cinq.Le Secrétaire-trésorier, 39103-3-2-o J.LÉO.BEAUDET.Given at Ste-Scholastique on this eleventh dav of January nineteen hundred and fifty-five.J.LÉO.BEAUDET, 39103-3-2-o Secretary-Treasurer.Province de Québec Province of Quebec Municipalité du comté de Champlain Municipality of the county of Champlain Avis public est donné à tous les contribuables et intéressés dans la municipalité du comté de Champlain, par le soussigné, secrétaire-trésorier, domicilié en la paroisse de Ste-Geneviève de Batiscan, que les immeubles ci-dessous mentionnés seront vendus à l'enchère publique, en cette dite paroisse de Ste Geneviève, au lieu où le conseil de comté tient ses sessions, JEUDI, le DIXIÈME jour du mois de MARS prochain, (1955), ?i DIX heures de l'avant-midi, pour cotisations et taxes dues, à moins qu'elles ne soient payées avec les frais, avant la vente.Public notice is hereby given to all tax-payers and interested parties in the Municipality of the county of Champlain, by the undersigned, Secretary-Treasurer, domiciled in the parish of Sainte-Geneviève de Batiscan, taht the immoveable property hereinunder mentioned, will be sold {at public auction in the said parish, at the place where the county Council holds its sittings, on THURSDAY, the TENTH of MARCH next (1955) at TEN o'clock in the forenoon for assessments and taxes due, unless said taxes and assessments be paid, with costs, before said sale.Dans la municipalité du village de Parent \u2014 In the municipality of the village of Parent Propriétaire Owner \tTaxes\t\tTaxes\t\t Désignation\tmunie.\t\tscol.\t\t \t\t\t\u2014\tTotal\t Description\tMunie.\t\tSchool\t\t \ttaxes\t\ttaxes\t\t No 20, bloc-block E., cad village\t«53\t86\t$116.40\t8170\t26 de-of Parent.\t\t\t\t\t No 19, bloc-block E, cad.village\t12\t94\t7.83\t20\t77 de-of Parent.\t\t\t\t\t No 40, bloc-block K, car.village\t1\t40\t6.19,\t7\t69 de-of Parent.\t\t\t\t\t No 3, bloc-block 7, car.village de-\t244\t00\t433.40\t677\t46 of Parent.\t\t\t\t\t No 14, bloc-block B, cad.village\t1\t31\t3.88\t5\t19 dc-of Parent.\t\t\t\t113\t No 15, bloc-block B, cad.village de-of Parent.\t26\t30\t87.12\t\t42 \t\t\t\t\t No 83, bloc-block E, cad.village\t47\t25\t29.10\t76\t36 dc-of Parent.\t\t\t\t\t No 128, bloc-block E, cad.village\t4\t73\t2.97\t7\t70 de-of Parent.\t\t\t\t\t No 92, bloc-block B, cad.village\t83\t97\t36.13\t120\t10 de-of Parent.\t\t\t\t\t 100, bloc-block K, cad.village de-\t3\t50\t3.78\t7\t28 of Parent.\t\t\t\t\t 150, bloc-block B, cad.village de-\t1\t40\t1.51\t2\t91 of Parent.\t\t\t\t\t Emile Beaudoin.Emile Beaudoin.Burpy Rugglcs.Rodolphe Dupont.Jacques Lemay.Jacques Lemay.Delphis Bolduc.Delphis Bolduc.Mme-Mrs W.Cossette Paul Juair.Eugenie Roy.Dans la municipalité de la paroisse de St-Maurice In the municipality of the parish of St-Maurice Mme-Mrs Eugene Vaillancourt.Zotiquc Vaillancourt.P.52 du cadastre de St-Maurice, 6W arp- en superficie, borné au sud par les terres du Cap de la Madeleine, et de tods autres côtés par résidu du lot No 52\u2014P.52 of the cadastre of St.Maurice G}4 arP- hi superficial area, bounded on the south by the farms of Cap de la Madeleine and on all other sides by the residue of lot No.52.P.52, car.St-Maurice, Q}4 arp.en superficie, borné au sud par les terres du Cap de la Madeleine, à l'ouest par le No 56, à l'est 3.34\t5.37\t8.71 \t\t 3.34\t5.37\t8.71 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.8 243 Propriétaire Owner\tDésignation Description\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tTotal \tet au nord par résidu du lot No 52.\u2014P.52 cad.St.Maurice, 0}4 arp.in superficial area, bounded on the south by the farms of Cap de la Madeleine, on the west, by No.50, on the east and on the north, by the residue of lot No.52.\t\t\t Dans la municipalité de la paroisse de St-F.-X.de Batiscan In the municipality of the parish of St-F.-X.of Batiscan\t\t\t\t Chs.Aug.JHébert.\t403, cad.St-F.-X.de-of Batisoan 404, cad.St-F.-X.de-of Batiscan 405, cad.St-F.-X.de-of Batiscan Les lots Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 d'une subdivision du lot No 182, et le lot No 1 d'une subdivision du lot No 132, cad.St-F.-X.de Batiscan \u2014 Lots Nos 1, 2, 3, 4, 5, 0, 7, 8, 9, 10, 11 of a subdivision of lot No.182, and lot No.1 of a subdivision of lot No.132, cad.St-F.-X.of Batiscan.\t2.35 0.84 0.84 40.60\t5.84 2.50 2.56 112.01\t8.19 3.40 3.40 152.67 DansMa municipalité scolaire de Grand'Mère \u2014 In the school municipality of Grand'Mère\t\t\t\t \t130-172, cad.Stc-Flore.\t\t0.79 168.11 0.99 103.SI 001.92 42.02\t0.79 168.11 0.99 103.81 601.92 42.02 \tP.G et P.7 cadastre Ste-Flore\t\t\t \tsur la 5è Avenue, borné en front par la 5è Avenue, au N.E.par Mme Léo Grenier et au S.O.par Ambroise Jacob \u2014 Pt.6 and Pt.7 cadastre Stc-Floro on 5th Avenue, bounded in front by 5th Ave.on tho N.E.by Mrs Léo Grenier, and on the S.W., by Ambroise Jacob.137-191 cad.Ste-Florc.\t\t\t \tP.94 sur la 7è Avenue (cad.Ste-Flore), borné au N.E.par Frank I lagan, en profondeur par la ri-' vière Welsh et au S.O.par Gaston Cournoyer \u2014 Pt.94 on 7th Ave.(Cad.Ste-Flore), bounded on the N.E.by Frank Hagan, in depth by the Welsh River, and on the S.W.by Gaston Cournoyer.P.139 cad.Ste-Flore, sur la 8è Avenue; borné en front par la 8ô Avenue, du côté S.O.par Joseph Garccau, et du côté N.E.liar Hector Ricard \u2014 Pt.139 cad.Ste-Flore, on 8th Ave.; bounded in front by 8th Avenue, on the S.W.side, by Joseph Garceau, and on the N.E.side by Hector Richard.138-79 et-and 139-91 cad Ste-Flore.\t\t\t \t\t\t\t Dans la municipalité do la paroisse de Ste-Geneviève de Batiscan In the municipality of the parish of Ste-Geneviève of Batiscan\t\t\t\t fc>\tP.554 cadastre Ste-Geneviève de Batiscan, borné comme suit: en front au chemin public, en profondeur à Wilfrid Massicotte, d'un côté à Alfred Despins, et de l'autre côté à Wilfrid Massicotte, avec bâtisses dessus \u2014 Pt.554 cadastre Ste-Geneviève of Batiscan, bounded as follows: in front by the public highway, in depth, by Wilfrid Massicotte, on one side, by Alfred Despins, and on the other side, by Wilfrid Massicotte, with buildings thereon.\t4.19\t5.63\t9.82 244 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 Bureau de La Corporation du comté de Champlain, Ste-Geneviève de Batiscan, ce septième jour du mois de janvier de l'année mil neuf cent cinquante-cinq.Le Secrétaire-trésorier, C.M.C.C., 39I06-3-2-o A.-J.-0.BERGERON.Office of The Corporation of the county of Champlain, Sainte-Geneviève de Batiscan this seventh day of the month of January, of the year one thousand hundred and fifty-five.A.-J.-O.BERGERON, 39106-3-2 Secretary-treasurer, C.M.C.C.Action en séparation de biens .Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 366526.Dame Sarah Gordon, de la cité et district de Montréal, épouse commune en biens de Morris Magid, marchand, de la même place, demanderesse, vs ledit Morris Magid, défendeur.Prenez avis qu'une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 14ième jour de Janvier 1955.Montréal, le 14 janvier 1955.Le Procureur de la demanderesse, 39075-o J.H.FREEDMAN.Arrêtés en Conseils ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF- Numéro 25 Québec, le 5 janvier 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"Ç^_^ Concernant des modifications au décret relatif aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans le comté de Chicoutimi.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil' des modifications au décret numéro 1296 du 15 décembre 1952, amendé par les arrêtés numéros 1375-E du 23 décembre 1953 et 499-C du 13 mai 1954, relatif aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans le comté de Chicoutimi; Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 10 juillet 1954; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 1296, soit modifié comme suit: >\"« 1° L'énumération des parties contractantes est modifiée pour se lire comme suit: D'une part: L'Association patronale des barbiers, coiffeurs et coiffeuses du comté de Chicoutimi, Inc.; L'Association patronale des barbiers, coiffeurs et coiffeuses du comté de Lac Saint-Jean, Inc.; Action for Separation as to Property Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.366526.Dame Sarah Gordon, of the city and district of Montreal, wife common as to property of Morris Magid, merchant, of the same place, plaintiff, vs the said Morris Magid, defendant.Take notice that an action in separation as to property has been instituted in this case on the 14th day of January, 1955.Montreal, January 14th, 1955.J.H.FREEDMAN, 39075-o Attorney for the plaintiff.Orders in Council ORDER IN OUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 25 Quebec, January 5th, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Fart \"C\" Concerning amendments of the decree relating to the barber and hairdressing trades in the county of Chicoutimi.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the decree No.1296 of December 15th, 1952, amended by Orders in Council Nos.1375-E of December 23rd, 1953 and 499-C of May 13th, 1954, relating to the barber and hairdressing trades in the county of Chicoutimi; Whereas the said notice has been published in the Quebec Official Gazette, issue of July 10th, 1954; Whereas no objections has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, No.1296, be amended as follows: 1.The enumeration of contracting parties is amended to read as follows: On the one part: \"L'Association .patronale des barbiers, coiffeurs et coiffeuses du comté de Chicoutimi, inc.\" \"L'Association patronale des barbiers, coiffeurs et coiffeuses du comté de Lac Saint-Jean, inc.\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 245 Et, d'autre part: Le Syndicat des employés barbiers, coiffeurs et coiffeuses du comté de Chicoutimi, Inc.; 2° L'article II est remplacé par le suivant: \"IL Juridiction territoriale: Le présent décret s'applique à tout le district électoral de Chicoutimi.Dans le district électoral de Lac Saint-Jean, il s'applique également aux villes d'Alma, Ile Maligne, Naudville et Riverbend, aux municipalités de Saint-Jérôme et Saint-Êmilien (Desbiens Mills) et au territoire compris dans un rayon de deux (2) milles de leurs limites.\" 3° L'article II-A est remplacé par le suivant: \"II-A.Juridiction professionnelle: La juridiction professionnelle du décret s'étend à toute personne qui exécute elle-même ou fait exécuter par un salarié un travail faisant l'objet du décret.\" \u2022 4° Les paragraphes \"a\" et \"b\" de l'article III sont remplacés par les suivants: \"III.Durée du travail: Les heures régulières de travail sont réparties comme suit pour toutes les catégories de salariés: o) Pour les barbiers coiffeurs pour hommes: Pour les fins du présent article seulement, la juridiction territoriale est divisée en cinq (5) zones de la façon suivante: Zone 1: La cité de Chicoutimi, les villes de Jonquière, Chicoutimi-Nord et Kénogami, la municipalité de Ilivière-du-Moulin et le territoire compris dans un rayon de cinq (5) milles de leurs limites, excepté la cité d'Arvida.Zone 2: La cité d'Arvida.Zone 3: Les villes de Bagotville et de Port Alfred, la' municipalité de Grande-Baie et le territoire compris dans un rayon de cinq (5) milles de leurs limites.Zone 4-' Les villes d'Alma, Naudville, Ile Maligne et Riverbend et les municipalités de Saint-Jérôme et de Saint-Émilien (Desbiens Mills) et le territoire compris dans un rayon de deux (2) milles de leurs limites.Zone 5: Tout le territoire non compris, dans les quatre (4) premières zones.Zone 1 Cinquante et une heures et demie (513^) par semaine réparties de la façon suivante: Le lundi: de 8.00 a.m.à midi.Les mardi, mercredi, jeudi et samedi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Le vendredi et les veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 9.30 p.m.Les trois jours précédent la veille de Noël: de 8.00 a.m.à 9.30 p.m.La veille de Noël et du Premier de l'an: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Zone 2 Cinquante et une heures et demie (513^) par semaine réparties de la façon suivante: Le lundi: de 8.00 a.m.à midi.Les mardi, mercredi, jeudi et samedi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Le vendredi et les veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 9.30 p.m.Les deux jours précédent la veille de Noël et du Premier de l'An: de 8.00 a.m.à 9.30 p.m.La veille de Noël et du Premier de l'An: de 8.00 a.m.à 6.00 P-m.Zone 3 Cinquante-deux heures et demie (523^) par semaine réparties de la façon suivante: And, on the other part: \"Le Syndicat des employés barbiers, coiffeurs et coiffeuses du comté de Chicoutimi, inc.\" 2.Section II is replaced by the following: \"II.Territorial jurisdiction.The present decree applies to the entire constituency of Chicoutimi.In the constituency of Lake St.John, it also applies to the towns of Alma, He Maligne, Naudville and Riverbend, to the municipalities of St.Jérôme and St.Emilien (Desbiens Mills) and to the territory comprised in a radius of two (2) miles from their limits.\" 3.Section II-A is replaced by the following: \"II-A.Professional jurisdiction: The professional jurisdiction of the decree extends to all persons doing themselves work governed by the decree or having such work done by an employee.\" 4.Subsections \"a\" and \"6\" of section III are replaced by the following: \"III.Duration of work: The standard hours of work are distributed as follows for all categories of employees: a) Mens ,barbers and hairdressers: For the purposes of the present section only, the territorial jurisdiction is divided into five (5) zones as follows: Zone 1: The city of Chicoutimi, the towns of Jonquière, Chicoutimi-Nord and Kénogami, the municipalities of Rivière-du-Moulin and the territory comprised in a radius of five (5) miles from their limits, with the exception of the city of Ar-vida.Zone 2: The city of Arvida.Zone 3: The towns of Bagotville and Port Alfred, the municipality of Grande-Baie and the territory comprised in a radius of five (5) miles from their limits.Zone 4- The towns of Alma, Naudville, He Maligne and Riverbend and the municipalities of St.Jérôme and St.Êmilien (Desbiens Mills) and the territory comprised in a radius of two (2) miles from their limits.Zone 5: The entire territory not comprised in the other four (4) zones.Zone 1« Fifty-one and a half (513^) hours per week, distributed as follows: Monday: 8.00 a.m.to 12.00 a.m.(noon).Tuesday, Wednesday, Thursday and Saturday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday and holiday eves: 8.00 a.m.to 9.30 p.m.The three days preceding Christmas Eve: 8.00 a.m.to 9.30 p.m.Christmas Eve and New Year's Eve: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Zone 2 Fifty-one and a half (513^) hours per week, distributed as follows: Monday: 8.00 a.m.to 12,00 a.m: (noon).Tuesday, Wednesday, Thursday and Saturday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday and holiday eves: 8.00 a.m.to 9.30 p.m.The two days preceding Christmas Eve and New Year's Eve: 8.00 a.m.to 9.30 p.m.Christmas Eve and New Year's Eve: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Zone 3 Fifty-two and a half (523^) hours distributed as follows: 246 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 8 Le lundi: de 8.00 à midi; Les mardi, mercredi et jeudi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.; , Les vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 8.00 p.m.; L'avant-veille de Noël et du Premier de l'An: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.; La veille de Noël et du Premier de l'An: de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.Zone 4 Cinquante-deux heures (52) par semaine réparties de la façon suivante: Le lundi: de 8.00 a.m.à midi; Les mardi, mercredi, jeudi et samedi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.; Le' vendredi et les veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.; Les trois jours précédent la veille de Noël* de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.La veille de Noël et du Premier de l'An: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Zone 5 Cinquante-huit heures (58) par semaine réparties de la façon suivante : Le lundi: de 8.00 a.m.à midi; Les mardi, mercredi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.; Le jeudi: de 8.00 a.m.à 8.00 p.m.; Les vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées, ainsi que les trois jours précédent Noël et le Premier de l'An: de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.Toutefois, dans les cinq zones, lorsque l'un des jours de fêtes chômées mentionnés à l'article IV, tombe un jour ouvrable autre que le lundi et le mardi, les heures de travail du lundi de cette semaine sont de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Si un de ces jours de fêtes chômées tombe le mardi, les heures de travail du lundi sont alors celles prévues pour la veille des fêtes chômées.b) Pour les coiffeurs et coiffeuses pour dames: Pour les.fins du présent article seulement, la juridiction territoriale est divisée en trois (3) zones et de la façon suivante: Zone 1: La cité de Chicoutimi, les villes de Chicoutimi-Nord, Jonquière, Kénogami, Arvida, Bagotville et Port-Alfred, les municipalités de Rivière-du-Moulin et de Grande-Baie, et le territoire compris dans un rayon de cinq (5) milles de leurs limites.Zone 2: Les villes d'Alma, Naudville, Ile Maligne et Riverbend, les municipalités de Siint-Jérôme (Métabetchouan) et Saint-Émilien (Desbiens Mills) et le territoire compris dans un rayon de deux (2) milles de leurs limites.Zone 3: Tout le territoire non compris dans les deux (2) premières zones.Zone 1 Cinquante-deux heures (52) par semaine réparties de la façon suivante: Les lundi, mardi, mercredi et jeudi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.; Les vendredi et veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.; Le samedi: de 8.00 a.m.à midi; Toutefois, aux dates ci-après mentionnées, les heures de travail sont les suivantes : Les 22, 23, 29 et 30 décembre: de 8.00 a.m à 10.00 p.m.; Les 24 et 31 décembre: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m., ainsi que la veille de Pâques.Zone 2 Quarante-sept heures (47) par semaine réparties de la façon suivante: Monday: 8.00 a.m.to 12.00 (noon).Tuesday, Wednesday and Thursday: 8.00 a.m.to (3.00 p.m.Friday, Saturday and holiday eves: 8.00 a.m.to 8.00 p.m.The day before Christinas Eve and New Year's Eve: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.Christmas Eve and New Year's Eve: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.Zone 4 Fifty-two (52) hours per week distributed as follows: Monday: 8.00 a.m.to 12.00 (noon).Tuesday, Wednesday, Thursday and Saturday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday and holiday eves: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.The three davs preceding Christmas Eve: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.Christmas Eve and New Year's Eve: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Zone 5 Fifty-eight (58) hours per week distributed as follows: Monday: 8.00 a.m.to 12.00 (noon).Tuesday, Wednesday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Thursday: 8.00 a.m.to 8.00 p.m.Friday, Saturday and holiday eves, including the three days preceding Christmas and New Year's Day: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.However, in the five zones, when one of the holidays mentioned in section IV falls on a working day that is not a Monday or a Tuesday, the working hours of the Monday of that week shall be from 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Should one of such holidays fall on a Tuesday, the working hours on Monday shall be those established for a holiday eve.b) Ladies' male and female hairdressers: For the purposes of the present section only, the territorial jurisdiction is divided into three (3) zones as follows: Zone 1: The city of Chicoutimi, the towns of Chicoutimi-Nord, Jonquière, Kénogami, Arvida, Bagotville and Port-Alfred, the municipalities of Rivicre-du-Moulin and Grande-Baie and the territory comprised in a radius of five (5) miles from their limits.Zone 2: The towns of Alma, Naudville, He Maligne and Riverbend, the municipalities of St.Jérôme (Métabetchouan) and St.Emilien (Des-biens Mills) and the territory comprised in a radius of two (2) miles from their limits.Zone 3: All municipalities not included in the other two zones.Zone 1 Fifty-two (52) hours per week distributed as follows: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday and holiday eves: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.Saturday: 8.00 a.m.to 12.00 (noon).However, on the following dates, the hours of work shall be as follows: On December 22nd, 23rd, 29th and 30th: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.On December 24th and 31st: 8.00 a.m.to 6.00 p.m., including Easter Saturday.Zone 2 \u201e Forty-seven (47) hours per week distributed as follows: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, -January 22nd, 1955, Vol.87,lNo.3 , '! 247 Le lundi: de 1.00 p.m.à 6.00 p.m.; Les mardi, mercredi et jeudi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.; Le vendredi et les veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.; Le samedi: de 8.00 a.m.à midi; Toutefois, aux dates ci-après mentionnées, les heures de travail sont les suivantes: Les 22, 23, 29 et 30 décembre: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.; Les 24 et 31 décembre: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.; ainsi que la veille de Pâques.Zone 3 Cinquante heures (50) par semaine réparties de la façon suivante: Le lundi: 1.00 p.m.à 6.00 p.m.Lés mardi, mercredi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.; Le jeudi: de S.00 a.m.à 8.00 p.m.; Les vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées, ainsi que les 22, 23, 29 et 30 décembre: de 8.00 à 9.00 p.m.Les 24 et 31 décembre: de 8.00 a.m.a 6.00 p.m.5° L'alinéa 4 du paragraphe \"a\" de l'article XI est remplacé par le suivant: \"4.Dans tout salon de barbier, de coiffeuse ou de beauté, il est interdit d'avoir plus d'un apprenti.Cependant deux (2) enfants d'un même barbier, d'un même coiffeur ou d'iuic même coiffeuse peuvent compléter simultanément leur apprentissage dans un même salon.De plus, deux apprentis coiffeurs ou coiffeuses pour dames peuvent compléter simultanément leur apprentissage dans un même salon pourvu que ce salon ait à son emploi, régulièrement, c'est-à-dire cinq (5) jours par semaine à raison de \"huit (8) heures par jour, deux (2) salariées expérimentées possédant leur certificat de qualification.\" 6° L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe \"i\" de l'article XI: \"Tout apprenti qui se prévaut des dispositions de l'alinéa précédent doit s'enregistrer au préalable au Comité paritaire et se conformer aux présentes dispositions concernant l'apprentissage.\" (Document \"C\" annexé à l'arrêté) Grenier du Conseil Exécutif, 39063-o L.DÉSILETS.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 22 Québec, le 5 janiver 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Concernant des modifications au décret relatif aux métiers de barbier et de coiffeur dans la région de Montréal.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier et de coiffeur \"dans la région de Montréal, rendue obligatoire par le décret numéro 2162 du 20 août 1941, amendé par les arrêtés en conseil numéros 3007 et 3128 des 6 et 19 novembre 1941, 1295 du 29 mai 1942, 3020 du 21 octobre 1943, 999 du 28 mars 1944, 1363 du 6 avril 1945, 4455 et 4457 du 31 octobre 1946, 455-D et 2027-A des 27 mars et 10 décembre 1947, 108-A du 3 Monday: 1.00 p.m.to 6.00 p.m.Tuesday, Wednesday and Thursday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday and holiday eves: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.¦ Saturday: 8.00 a.m.to 12.00 (noon).However, on the following dates, the hours of work shall be as follows: On December 22nd, 23rd, 29th and 30th: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.On December 24th and 31st: 8.00 a.m.to 6.00 p.m., including Easter Saturday.Zone 3 Fifty (50) hours per week distributed as follows: Monday: 1.00 p.m.to 6.00 p.m.Tuesday, Wednesday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Thursday: 8.00 a.m.to 8.00 p.m.Friday, Saturday and holiday eves, including December 22nd, 23rd, 29th, 30th: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.December 24th and 31st: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.5.Paragraph 4 of subsection \"a\" of section XI is replaced by the following: \"4.There shall not be more than one apprentice in a barber shop or hairdressing beauty parlour.Howe\\jpr, two children of a same barber or hairdresser may complete simultaneously their apprenticeship in a same parlour.Also, two ladies' hairdresser apprentices may complete simultaneously their apprenticeship in a same parlour providing such parlour employs regularly, i.e.five (5) days per week \u2014 eight (8) hours per day, two (2) qualified workers holding their certificate of competency.\" 6.The following paragraph is added to subsection \"i\" of section XI: \"Every apprentice availing himself of the provisions of the foregoing paragraph shall first register with the Parity Committee and observe the present provisions relating to apprenticeship.\" (Document \"C\" annexed to the order).L.DÉSILETS, 39063-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 22 Quebec, January 5th, 1955.Present: The Lieutenant Governor in Council.Concerning amendments of the decree relating to the barber and hairdrcss trades in the region of Montreal.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the barber and hairdresser trades in the region of Montreal, rendered obligatory by the decree number 2162 of August 20, 1941, as amended by Orders 3007 and 3128 of November 6 and 19, 1941, 1295 of May 29, 1942, 3020 of October 21, 1943, 999 of March 28, 1944, 1363 of April 6, 1945, 4455 and 1157 of October 31, 1946, 545-D and 2027-A of March 27 and December 10, 1947, 108-A of February 3, 1949, 248 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 8 février 1949, 515-C et 1155-B des 3 mai et 19 octobre 1950, 382-B du 12 avril 1951 et 503-C du 7 mai 1952, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 15 août 1953; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 2162, soit modifié comme suit: 1° Le paragraphe \"a\" de l'article IV est remplacé par le.tsuivant: \"a) Les taux de salaires minima suivants doivent être payés: Pour chaque compagnon barbier-coiffeur régulier: trente-trois dollars ($33.00) par semaine, plus une commission de 50% sur les recettes de son travail excédant quarante-trois dollars ($43.-00) par semaine.Pour chaque compagnon barbier-coiffeur surnuméraire: $0.85 pour chaque heure de travail, plus une commission de 10% sur toutes les recettes brutes de son travail.Toutefois, lorsque les recettes de son travail atteignent ou excèdent la somme de quarante-trois dollars ($43.00) et que ledit salarié a travaillé pendant trente (30) heures ou plus durant la semaine, il doit être rémunéré au même tarif que le compagnon barbier-coiffeur régulier.\" 2° A l'article V, les prix minima ci-après mentionnés sont substitués à ceux qui apparaissent actuellement dans le décret pour chacun des services concernés, à savoir: \"Coupe de cheveux pbur adultes des deux sexes: Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.S0.70 Les samedi et veilles des fêtes chômées \u201e spécifiées dans le présent décret.0.75 Coupe de cheveux pour enfants des deux sexes de moins de 15 ans: Les lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.40 Les vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées spécifiées dans le présent décret.0.55\" 3° Le paragraphe \"o\" de l'article VI est remplacé par le suivant:.\"o) Le salaire hebdomadaire de l'apprenti est le suivant: Du 4ème au 6ème mois d'apprentissage, ou de la sortie du Centre d'Apprentissage au 6ème mois $16.00 par semaine; Deuxième semestre: $19.00 par semaine, plus 10%.de commission sur les recettes supérieures à $29.00; Troisième semestre: $22.00 par semaine, plus 20% de commission sur les recettes supérieures à $32.00; Quatrième semestre: $25.00 par semaine, plus 30% de commission sur les recettes supérieures à $35.00; Cinquième semestre: $28.00 par semaine, plus 40% de commission sur les recettes supérieures à $38.00; Sixième semestre : $32.00 par semaine, plus 50% de commission sur les recettes supérieures à $42.00.\" 4° L'article VIII-A est remplacé par le suivant: 515-C and 1155-B of May 3 and October 19, 1950, 382-B of April 12, 1951 and 503-C of May 7, 1952, have submitted to the Minister of Labour a request to amend the said decree; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of August 15, 1953; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said decree, number 2162, be amended as follows: - 1.Subsection \"a\" of section IV is replaced by the following: \"a) The minimum rates of wages shall be as follows : For every regular journeyman barber-hairdresser, thirty-three dollars ($33.00) per week plus a 50% commission on the receipts of his work exceeding forty-three dollars ($43.00) per week.For every occasional journeyman barber-hairdresser: $0.85 per hour plus a 10% commission on the gross receipts of his work.However, when the receipts of his work attain or exceed the amount of forty-three ($43.00) dollars and when the said employee has worked a minimum of 30 hours during the week, he shall be paid the rate of the regular journeyman barber-hairdresser.\" 2.In section V, the minimum prices hereafter mentioned are substituted for those actually mentioned in the decree for each one of the services concerned, namely: \"Haircut for adults, male and female: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.$0.70 Saturday and eves of holidays mentioned in the present decree.0.75 Haircut for children, male and female, under 15 years of age: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.0.40 Friday, Saturday and eves of holidays mentioned in the present decree 0.55\" 3.Subsection \"o\" of section VI is replaced by the following: \"o) The weekly wages of apprentices shall be as follows : From the 4th to the 6th month of apprenticeship, or from the time the apprentice leaves the apprenticeship center to the 6th month: $16.00 per week; Second six months: $19.00 per week plus 10% commission on receipts exceeding $29.00; Third six months : $22.00 per week plus 20% commission on receipts exceeding $32.00; Fourth six months: $25.00 per week plus 30% commission on receipts exceeding $35.00; Fifth six months: $28.00 per week plus 40% commission on receipts exceeding $38.00; Sixth six months: $32.00 per week plus 50% commission on receipts exceeding $42.00.\" 4.Section VLTI-A is replaced by the following: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1965, Vol.87, No.3 249 \"VHI-A.Vacances payées: L'employeur doit donner une semaine de vacances payées, au taux de trente-six (S36.00) dollars, à tout compagnon barbier-coiffeur régulier qui a été à son service pendant une année entière, sans perte de temps, sauf pour des raisons valables.Si le compagnon barbier-coiffeur a servi moins d'une année, il a droit à une rémunération de vacances équivalente à'1/12 du salaire de trente-six (836.00) dollars pour chaque mois de service sans perte de temps, sauf pour des raisons valables.L'employeur doit donner une semaine de vacances payées à tout apprenti ayant été à son service pendant une année.Le taux de rémunération de vacances pour l'apprenti est celui auquel il a droit à la date d'échéance de ses vacances; toutefois, lorsque l'apprenti a servi moins d'une année, il a droit à 1/12 de son salaire de base pour chaque mois de service sans perte de temps, sauf pour des raisons valables.Lorsqu'un employeur se trouve dans l'impossibilité de trouver un remplaçant à un compagnon-barbier-coiffeur pour la durée de ses vacances, il lui est permis, avec le consentement du Comité paritaire, de remplacer la semaine de vacances par un boni égal au taux de salaire de vacances.\u2022 Pour chaque congé annuel pris et payé, ou remplacé par un boni, l'année de service d'un salarié s'établit à compter de la date de son entrée au service pour le même employeur.Dans le cas de vente ou de transfert d'un salon de barbier, le nouveau propriétaire et employeur assume toutes les obligations de l'employeur précédent envers tout compagnon barbier-coiffeur régulier ou apprenti ' relativement aux vacances payées.L'employeur doit faire connaître au salarié, au moins deux (2) semaines à l'avance, le date fixée pour ses vacances; la rémunération de vacances est payable au salarié avant son départ en vacances.\" Le Greffier du Conseil Exécutif, 39063-o L.DÉSILETS.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 25 Québec, le 5 janvier 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"F\" Concernant un amendement au règlement de prélèvement du Comité paritaire des barbiers, coiffeurs et coiffeuses, juridiction de Chicoutimi.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le règlement de prélèvement du Comité paritaire des barbiers, coiffeurs et coiffeuses, juridiction de Chicoutimi, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 191-B du 11 mars 1954, soit amendé comme suit: La première phrase du paragraphe \"c\" de la section 1, intitulée \"Cotisation\", est remplacée par la suivante: \"c) Tous les artisans assujettis audit décret numéro 1296 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une cotisation de ^ de 1% basée sur une rémunération hebdomadaire de $60.00.\" (Document \"F\" annexé à l'arrêté).Le Greffier du Conseil Exécutif, 39063-o L.DÉSILETS.\"VIII-A.Vacation with pay: The employer shall give a vacation of one week with pay, at the rate of thirty-six dollars ($36.00), to every regular barber-hairdresser journeyman who has been a whole year in his employ, without loss of time, except for good reasons.In the event that a journeyman barber-hairdresser has worked less than one year, he is entitled to a vacation pay of 1/12 the wages of thirty-six ($36.00) dollars for each month of service without loss of time, except for good reasons.The employer shall give a week of vacation with pay to every apprentice with one year of service.The rate of vacation pay for the apprentice shall be that to which he is entitled at the date of his vacation; however, when the apprentice has had less than one year of service, he is entitled to 1/12 of his basic wages for each month of service without loss of time, except for good reasons.When an employer is unable to replace a journeyman barber-hairdresser for the duration of his vacation, he may, with the consent of the Parity Committee, replace the vacation week by a bonus equal to the vacation pay.For every annual vacation taken and paird, or replaced by a bonus, the year of service of an employee is computed from the date of employment by the same employer.In the event of the sale or transfer of a barber-hairdresser parlor, the new owner and employer assumes the duties of the previous employer towards every regular journeyman barber-hairdresser or apprentice as regards vocation with pay.The employer shall notify the employee, at least two (2) weeks in advance, of the date of his vacation; vacation pay is payable before the vacation.\" L.DÉSILETS, 39063-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 25 Quebec, January 5th, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"F\" Concerning an amendment to the levy by-law of the Barbers and Hairdresser Parity Committee, jurisdiction of Chicoutimi.It is ordered, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the levy by-law of the Barbers and Hairdressers Parity Committee, jurisdiction of Chicoutimi, approved by Order in Council No.191-B of March 11, 1954, be amended as follows: The first sentence of subsection \"c\" of part 1, headed \"Assessments\" is replaced by the follow-wing: \"c) All artisans subject to the said decree, No.1296 and amendments, shall pay to the Parity Committee an assessment of % of 1% based on the weekly remuneration of $60.00.\" (Document \"F\" annexed to the order).L.DÉSILETS, 39063-o Clerk of the Executive Council. 250 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 12L7 Québec, le 15 décembre 1954.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Concernant la circulation en forêt.Attendu qu'en vertu de l'article 144 de la Loi des terres et forêts, il est obligatoire, sur proclamation du Lieutenant-gouverneur en Conseil, de se munir au préalable d'un permis de circulation pour pénéter ou circuler dans une région sauvegardée, pendant Une période de temps comprise entre le 1er avril et le 15 novembre; Il est on donné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre des Terres et Forêts: Que la circulation dans les régions sauvegardées soit régie par les règlement suivants: 1° Le permis de circulation est gratuit; il devient nul lorsque la région sauvegardée pour laquelle il est émis est fermée à la circulation; 2° Le permissionnaire est tenu, sur demande, de montrer son permis et de prouver son identité à tout garde-feu, tout garde-pêche ou garde-chasse, tout officier du Service Forestier, tout constable ou tout officier de la paix; 3° A moins de dispositions contraires, il est permis de faire du feu dans la forêt ou à moins d'un demi-mille de la forêt, pour se chauffer ou faire cuire des aliments.Dans ce cas, on devra: a) choisir un endroit propice, jamais sous un arbre et de préférence près d'un lac ou d'un cours d'eau ; 6) nettoyer l'endroit en enlevant du sol, dans un rayon de quatre (4) pieds, toute terre végétale, tous bois morts et toutes branches, broussailles et feuilles sèches; c) éteindre complètement le feu avant de mutter l'endroit; d) s'abstenir totalement de faire de tels feux quand il vente fort ou lorsqu'il est à craindre que le feu ne provoque un incendie.4° Il est défendu de fumer en travaillant ou en circulant à pied, a cheval, en voiture, en automobile ou autres véhicules.Il est cependant permis de fumer au repos, dans un endroit approprié, c'est-à-dire libre de toute matière inflammable, prenant soin d'éteindre complètement toute matière enflammée, avant de quitter l'endroit ou de se remettre au travail; 5° Il est interdit de faire des feux pour chasser les moustiques autrement que dans un contenant métallique, et tel contenant doit être placé en un endroit débarrassé de toute terre végétale, tous débris ligneux et broussailles sur un rayon de quatre (4) pieds; ces feux doivent être complètement éteints avant de quitter les lieux; 6° Lorsqu'une région sauvegardée est fermée à la circulation, il est interdit d'y faire des feux à ciel ouvert pour quelque besoin que ce soit, et de fumer en dehors des camps; 7° II est défendu de détruire, endommager ou enlever les affiches ayant trait à la protection des forêts contre le feu, les lignes téléphoniques, bâtisses et équipement servant à la protection des forêts; 8° Toute personne qui découvre un incendie en forêt doit l'éteindre immédiatement ou, au cas d'impossibilité, avertir le garde-feu le plus rapproché et prêter son concours; ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1217 Quebec, December 15th, 1954.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning travelling in forests.Whereas by virtue of article 144 of the Lands and Forests Act, it is obligatory, by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, to be provided with a travel permit to penetrate or circulate in a fire district, during a period of time comprised between April 1st and November 15th; It is ordered, therefore, upon the proposition of the Honourable the Minister of Lands and Forests: That travelling in fire districts be regulated by the following by-laws: 1.A travel permit is free of charge; it becomes void when the fire district for which it is issued is closed to traffic; 2.The holder of a travel permit must, upon request, show his permit and prove his identity to any fire-warden, forest-ranger or game-keeper, any officer of the Forestry Service, any constable or any officer of the Peace; 3.Unless otherwise provided for, it is lawful to make a fire in the Forest or at least at a distance of one-half mile from the forest, to warm themselves or cook food.In which case, one should: a) select a suitable spot, never under a tree, and preferably near a lake or a water-course; b) clear the place by removing from the soil, within a radius of four (4) feet, all vegetable matter, all dead wood and all branches, brushwood and dry leaves; c) totally extinguish the fire before quitting the place; d) to totally abstain from making such fires when there is a heavy wind blowing or where there is fear that fire will provoke a conflagration.4.It is forbidden to smoke while working or travelling on foot, on horse-back, in a carriage, in an automobile or in other vehicles.It is allowed, however, to smoke while at rest, in an appropriate place, that is to say, free of all inflammable material, taking care to completely extinguish all bla/.ing material, before quitting the place or resuming work; 5.It is forbidden to make fires for the extermination of flies or mosquitoes, otherwise than in a metallic container and such a container should be placed in a spot cleared of all vegetable matter, all woody and brush-wood debris within a radius of four (4) feet; these fires should be completely extinguished before leaving the premises; 6.When a fire district is closed to traffic, it is forbidden to make fires in the open for anyneed whatsoever and to smoke outside of camps; 7.It is forbidden to destroy, damage or remove posters respecting fire protection of the forests, telephone lines, buildings and equipment used in fire protection; 8.Any person who discovers a fire in the forest should immediately extinguish it or, when this is impossible, advise the nearest fire-ranger and give his assistance; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.8 251 9° Toute infraction aux presents règlements, si aucune peine spéciale n'est prescrite, rend le contrevenant passible des peines prévues par l'article 144 de la Loi des terres et forêts; 10° Toute personne, sous le coup d'une condamnation pour infraction aux présents règlements, perd le droit de pénétrer ou de demeurer en forêt durant la même année.Les présents règlements abrogent, à toute fin que ce soit, l'arrêté en conseil numéro 2094, du 21 août 1942.Le Greffier du Conseil Exécutif, 39079-o L.DÉSILETS.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1218 Québec, le 15 décembre 1954.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Concernant les scieries en forêt.Attendu Qu'en vertu de l'article 86 de la Loi des terres et forêts, les propriétaires de scieries situées sur les terres de la Couronne ou à moins d'un mille de distance de ces terres sont soumis à des obligations relatives à la protection des forêts contre le feu.Il est ordonné en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre des Terres et Forêts: Que l'établissement de l'opération de ces scieries soient régis par les règlements suivants: 1° Aucune personne ne peut établir de scierie sur les terres de la Couronne ni à moins d'un mille de distance de ces terres sans, au préalable, avoir obtenu un permis d'établissement du département des terres et forêts et avoir versé un dépôt de $100.00 en garantie.2° Si la scierie doit être établie sur les terres non aliénées de la Couronne, le permis d'établissement comporte la permission d'occuper le terrain concerné et dans ce cas le permissionnaire doit payer, comme rente d'occupation, le loyer annuel fixé par les règlements pour les terrains occupés pour fins industrielles.3° Si la scierie doit être établie sur un terrain patenté ou sur un lot sous billet de location, le propriétaire de la scierie doit déclarer qu'il est propriétaire du terrain ou, dans le cas contraire, qu'il a obtenu un permis d'occupation du propriétaire du terrain.4° Le concessionnaire forestier qui opère une scierie pour les besoins de son exploitation forestière et non pour des fins commerciales, à l'intérieur de sa concession, n'a pas de loyer à payer ni de dépôt garantie à effectuer étant donné qu'il paie déjà une rente foncière et que le renouvellement de son permis (licence) de coupe est conditionnel à l'observation des règlements, entre autres ceux qui concernent la protection des forêts et l'établissement des scieries.5° Si.la scierie doit fonctionner entre le 1er avril et le 15 novembre, aucun travail de construction ne doit être entrepris avant q'un défriché de 200 pieds de largeur, tout autour de la scierie, ait été établi et nettoyé de toute matière inflammable, q'une inspection des lieux ait été faite par un garde-feu et qu'un permis de construction ait été accordé.6° Aucune scierie ne peut être établie dans une tourbière.9.Any infringement of these present by-laws, should there be no special penalty prescribed, renders the contrevener liable to the penalties prescribed by article 144, of the Lands and Forests Act; 10.Any person, under accusation for infringement to the present by-laws, loses the right to penetrate or to stay in a forest during the same year.The present by-laws revoke for all purposes whatsoever Order in Council number 2094, of August 21st, 1942.L.DÉSILETS, 39079 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1218 Quebec, December 15th, 1954.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning sawmills in forests.Whereas under Article 86 of the Lands and Forests Act, owners of sawmills situate on Crown lands or less than a mile distant from such lands, are subject to obligations relative to forest fire protection.It is therefore ordered, upon the proposition of the Honourable Minister of Lands and Forests : That the establishment and operation of sawmills be governed by the following by-laws: 1.No person shall establish a sawmill on Crown lands nor within one mile from such lands without having previously obtained an establishment permit from the Department of Lands and Forests and to have made a deposit of $100.00 as a guarantee bond.2.Should the sawmill be established upon lands not alineated to the Crown, an establishment permit carries permission to occupy the land concerned and in such a case, the hoi.1er of a permit should pay, as occupational rental, the annual rent fixed by the by-laws for lands occupied for industrial purposes.3.If the sawmill is to be established upon patented land or upon a lot under ticket of location, the owner of the sawmill should declare that he is the owner of the land or, on the contrary, that he has obtained an occupational permit from the owner of the land.4.The timber-limit holder who operates a sawmill for the requirements of his forestry operations and not for commercial purposes within his concession, has no rent to pay nor to deposit any guarantee bond, considering he already pays a ground rent and that the renewal of his timber cutting license is contitional upon the observance of by-laws, amongst others, those which consern the protection of forests and the establishment of sawmills.5.If the sawmill is to operate between April 1st and November 15th, no construction work should be undertaken before a clearing of 200 feet of land is width, is made all around the sawmill, the said clearing having been established and cleared of all inflammable material, that an inspection of the premises has been made by a fire-warden and that a building permit has been granted.6.No sawmill may be established in a peatbog. 252 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° S 7° La scierie et ses dépendances doivent être pourvues des appareils les plus perfectionnés et les plus efficaces pour prévenir l'échappement du feu et des étincelles.8° Le propriétaire est tenu de maintenir en tout temps, à son établissement, une pompe d'une capacité minimum de 45 gallons à la minute à une pression de 90 livres; un minimum de 1200 pieds de boyau de pas moins de 1-3^\" de diamètre et autres accessoires nécessaires y compris une provision permanente de carburant et lubrifiant appropriés et 6 réservoirs en métal ou sacs en toile avec gicleurs, le tout maintenu en bon état, remisé dans un endroit convenable et pour usage exclusif en cas de feu.9° Entre le 1er avril et le 15 novembre, le bran de scie, les dosses et autres rebuts de la scierie ne peuvent être brûlés autrement que dans un vase clos avec cheminée munie d'un pare-étincelles dont les ouvertures ne doivent pas avoir plus d'un demi-pouce de diamètre, ou dans un brûleur fabriqué de parois métalliques enfoncées dans la terre jusqu'au sol minéral et dont la hauteur doit dépasser d'au moins quatre (4) pieds celle de la dalle qui amène les déchets au brûleur.10° Lorsque tous les déchets de la scierie ne peuvent être brûlés conformément aux dispositions du règlement N° 9, les dosses et rebuts, autres que le bran de scie, doivent être empilés en des endroits appropriés, à distance minimum de 50 pieds de la forêt, pour être ensuite brûlés à l'automne, à la fermeture de la saison de protection.A moins qu'on ne dispose d'un endroit propice pour le mettre en tas, le bran de scie doit être étendu uniformément sur l'emplacement de la scierie et recouvert d'une couche de terre à la fin des opérations.11° Tout propriétaire ayant opéré une scierie et fait le brûlage des déchets, à ciel ouvert, durant la période comprise entre le 16 novembre et le 31 mars suivant doit, après le 31 mars, même si la scierie n'est plus en opération, tenir permanence sur les lieux et à ses frais, un gardien et ce, aussi longtemps que l'organisation locale de protection des forêts peut l'exiger.Si le propriétaire néglige ou refuse de se conformer à cette disposition, l'organisation de protection des forêts aura le droit de placer ce gardien.Le propriétaire de la scierie devra payer tous les frais afférant à cette surveillance.12° Les bois empilés sur le terrain de la scierie doivent être placés à au moins 200 pieds de distance de la scierie et de la forêt.13° Entre le 1er avril et le 15 novembre, il est interdit à tout employé de fumer en travaillant sous peine des pénalités prévues par l'article 153 de la loi des terres et forêts.Il est cependant permis de fumer au repos, dans un endroit approprié, prenant soin d'éteindre complètement toute matière enflammée avant de se remettre au travail.14° Il est défendu de jeter le bran de scie, les dosses et autres rebuts de la scierie dans un lac ou un cours d'eau.15° Aucune scierie devant opérer entre le 1er avril et le 15 novembre ne peut être mise en opération avant qu'une inspection dudit établissement ait été faite par un garde-feu et qu'un permis d'opération ait été émis par l'organisation locale de protection des forêts.Ce permis est gratuit; il doit être continuellement affiché dans un endroit bien en vue de la scierie; il est renouvelable chaque année.16° Tout infraction aux présents règlements, si aucune peine spéciale n'est prescrite, entraîne la révocation du permis d'opération et le garde-feu doit prendre les moyens pour empêcher la 7.The sawmill and its dependencies should be provided with the most improved and efficient apparatus for preventing the escape of fire and sparks.8.The owner must have and maintain at all times in his establishment, a pump having a minimum capacity of 45 gallons to the minute at a présure of 90 pounds, a minimum of 1200 feet of hose of not less than in diameter and other necessary accessories in which are comprised a permanent provision of appropriate motor-fuel and oil and 6 reservoirs in metal or linen bags with sprinklers, the whole maintained in good order, to be stored in a suitable place and to be used exclusively in case of fire.9.Between April 1st and November 15th, sawdust, slags and other sawmill waste may not be burned otherwise than within a closed vessel with a chimney equipped with a fire-screen, the openings of which should not be more than one-half inch in diameter, or in a burner provided with metallic sides, dug into the subsoil and the height of which should exceed at least four (4) feet that of the chute which cerries the waste to the burner.10.When all the rubbish fo a sawmill cannot be burned in conformity with by-laws No.9, the slags and waste other than sawdust, should be piled in heaps in appropriate places, at a minimum distance of 50 feet from the forest, to be afterwards burned in the fall at the closing of the fire protection season.Unless a suitable place is available wherein it may be piled, sawdust must be spread evenly upon the emplacement of the sawmill and covered with a layer of dirt at the end of operations.11.Any owner having operated a sawmill and burned the rubbish in a open fire during the period comprised between November 16th and the following March 31st, should, after March 31st, even if the sawmill is no longer in operation, keep a permanent guardian upon the premises, at his own expenses and this should be for as long a period as the local organization for fire protection may demand it.Should the owner neglect or refuse to conform to this provision, the organization of fire protection will have the right to place this guardian.The sawmill owner shall pay all the assignable costs for such supervision.12.The wood piled on sawmill ground should be placed at a distance of at least 200 feet from the sawmill and the forest.13.Between April 1st and November 15th, it is forbidden for any employee to smoke while working under pain of penalties provided by article 153 of the Lands-and Forests Act.It is allowed, however, to smoke while at rest, in an appropriate place, taking care to completely extinguish all inflammable matter before starting work.14.It is forbidden to throw sawdust, slabs and other sawmill waste into a lake or watercourse.15.Any sawmill which shall operate between April 1st and November 15th cannot be put into operation before inspection of the said establishment* has been made by a fire-warden and that an operation permit has been issued by the local fire protection organization.This permit is free of charge; it should be continually posted in a visible and prominent place in the sawmill; it is renewable each year.16.Any infringement against the present bylaws, if no special penalty is prescribed, entails the cancellation of the operation permit and the fire-warden should take the means to prevent the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.8 253 scierie d'opérer, aussi longtemps que le propriétaire ne se sera pas conformé aux dits règlements.17° Quiconque opère une scierie sans permis d'opération ou après que son permis d'opération a été révoqué, est passible d'une amende de $10.00 pour chaque jour pendant lequel il est en défaut.En sus de l'amende, le juge peut ordonner la démolition de la scierie dans un délai d'un mois après le prononcé du jugement.18° Aucune scierie ne peut être vendue sans le consentement du Ministre des Terres et Forêts et le vendeur est tenu de faire connaître le nom et l'adresse de l'acquéreur.19° Le propriétaire, dont la scierie aura été la cause d'un incendie forestier, est responsable de tous les dommages causés par cet incendie et tous les frais d'extinction sont à sa charge.20° Lorsqu'une scierie aura été définitivement fermée, démolie ou abandonnée, le propriétaire sera tenu de nettoyer les lieux occupés paria-dite scierie, ses dépendances et la cour à bois, de tous les débris et rebuts, à la satisfaction du garde-feu; si le propriétaire refuse ou néglige de se rendre à ces exigences, le dépôt-garantie de $100.00 sera alors confisqué en tout ou en partie selon la recommandation du garde-feu qui devra faire exécuter les dits travaux de nettoyage et le propriétaire devra en acquitter tous les frais.21° Les mêmes règlements s'appliquent à toutes les scieries établies dans les forêts privées ou à une distance de moins d'un mille des forêts privées, si le Ministre juge la chose nécessaire.Le présent arrêté ministériel abroge, à toute fin que ce soit, l'arrêté en conseil 2095, du 21 août 1942.Greffier du Conseil Exécutif, 39079-o L.DÉSILETS.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1227 Québec, le 15 décembre 1954.Present: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil Concernant l'exécution de travaux en forêt.Attendu Qu'en vertu de l'article 153c de la Loi des terres et forêts, l'honorable Ministre des Terres et Forêts peut exiger que toute personne exécutant ou faisant exécuter en forêt des travaux appelés \"travaux publics\" comme les routes, les lignes de transmission, les chemins de fer, les barrages, les travaux miniers et industriels et tous les travaux autres que ceux qui relèvent des opérations forestières proprement dites, se conforme aux instruction et règlements du département des Terres et Forêts relatifs à la protection des forêts contre le feu.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre des Terres et Forêts: Que l'exécution de tels travaux soit régie par les règlements suivants: 1° Toute personne ou compagnie devant exécuter ou faire exécuter en forêt des travaux tels que ceux ci-haut décrits, est tenue d'en aviser le Service de la Protection au moins trente (30) jours d'avance, en spécifiant la nature et l'envergure des opérations, l'endroit où ils seront exécutés et la date de leur mise à exécution.sawmill from operating, as long as the owner shall not have conformed to the said by-laws.17.Whosoever operates a sawmill without an operation permit, or after his operation permit has been revoked, is subject to a fine of $10.00 for each day during which he is in default.In addition to the fine, the judge may order the demolition of the sawmill within a delay of one month after the pronunciation of the judgment.18.No sawmill should be sold without the consent of the Minister of Lands and Forests and the seller is obliged to make known the name and address of the purchaser.19.The owner whose sawmill was the cause of a forest fire is responsible for all damages caused by this fire and all fire extinguishing costs arc chargeable to him.20.When a sawmill has been definetcly closed, demolished or abandoned, the owner is obliged to clean the premises occupied by the said sawmill, its dependencies and the lumberyard of all rubbish and waste to the satisfaction of the firewarden; if the owner refuses or neglects to abide by these requirements, the guarantee-deposit of $100.00 shall then be confiscated, wholly or in part, in accordance with the recommendation of the fire-warden who shall see that the said clearing work is performed and the owner shall assume all costs thereof.21.The same by-aws apply to all sawmills established in private forests, or less than a mile distant from private forests, should the matter be deemed advisable by the Minister.The present Order in Council revokes, for all purposes whatsoever, Order in Council 2095 of August 21st, 1942.L.DÉSILETS, 39079 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1227 Quebec, December 15th, 1954.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the carrying out of operations in the forest.Whereas in accordance with section 153c of the Lands and Forests Act, the Honourable the Minister of Lands and Forests may require any person carrying out operations in the forest or causing same to be carried out, entitled \"public works\", such as roads, trasmission lines, railroads, dams, industrial and mining operations and any operations other than those which are included in forest operations properly speaking, to comply with the instructions and regulation of the Department of Lands and Forests concerning the protection of forests against fires.Consequently, it is ordained, upon the proposition of the Honourable the Minister of Lands and Forests: That the carrying out of such operations be governed by the following regulations: 1.Any person or company having to carry out operations in the forst or cause same to be carried out, such as those mentioned hereinabove, is compelled to advise the Protection Branch, at least thirty (30) days in advance, stating the nature and extent of said operations, the locality in which they shall be carried out and the date of commencement thereof, 254 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N?3 2° La protection des forêts contre le feu doit être faite par l'organisation locale de protection des forêts.Les frais de cette protection sont entièrement aux frais et à la charge de la personne pour le compte de laquelle ces travaux sont exécutés.3° Avant que lesdits travaux publics puissent être entrepris, l'organisation locale de protection des forêts doit préparer, de concert avec la personne ou compagnie exécutant ou faisant exécuter tels travaux, un plan d'organisation de protection et des moyens d'exécution devant être employés pour la prévention, la découverte et le combat des incendies forestiers; ce plan doit être soumis, pour approbation, à l'honorable Ministre des Terres et Forêts et les travaux ne peuvent être entrepris avant qu'un permis d'opération ait été amis par le Service de Protection des forêts sur la recommandation de l'organisation locale de protection des forêts.Ce permis peut être révoqué durant l'exécution des travaux si la personne ou la compagnie exécutant ou faisant exécuter lesdits travaux, néglige ou refuse d'appliquer ou de faire appliquer par tout son personnel les lois et règlements relatifs à la protection des forêts contre le feu.4° Un inspecteur, des assistants-inspecteurs, si nécessaire, et un nombre suffisant de gardes-feux doivent être engagés par ladite organisation de protection des forêts et nommés par l'honorable Ministre des Terres et Forêts pour assurer une surveillance efficace des travaux au point de vue de la protection des forêts contre le feu.5° Afin de conférer une plus grande autorité à ladite organisation de protection des forêts, les salaires des employés et toutes les autres dépenses encourues doivent être payés par cette organisation, quitte pour la personne pour le compte de laquelle ces travaux sont exécutés, de rembourser mensuellement les sommes affectées à ces fins.0° L'inspecteur ou l'officier en charge de fa protection, aura une responsabilité complète quant à la protection des forêts contre le feu et toute autorité dans l'organisation des rondes de patrouille, dans le contrôle du personnel à l'exécution de ces travaux, de même qu'au sujet de la main d'oeuvre, de l'outillage, de l'équipement, etc., à acquérir, selon le degré éventuel d'expension que pourrait prendre un incendie.7° Tout le matériel de lutte sera fourni par la personne pour le compte de laquelle ces travaux sont exécutés soit indirectement par l'organisation locale de protection des forêts, soit directement par la personne elle-même et distribué par l'inspecteur à des endroits propices en vue de servir «à toute éventualité en cas d'incendie forestier.8° Pour permettre une identification certaine, tous les employés à ces travaux doivent porter un permis de circulation en règle, ou tout autre sauf-conduit valide pour le travail seulement et reconnu comme équivalent par l'honorable Ministre des Terres et Forêts; lorsqu'ils seront requis de le faire par un garde-feu, un constable ou un officier de la paix, ces employés devront fournir un compte rendu de leurs allées et venues.9° Il est défendu de fumer en travaillant ou en circulant à pied, à cheval, en voiture, en automobile ou tous autres véhicules.Il est cependant permis de fumer au repos, dans un endroit approprié, prenant soin d'éteindre complètement toute matière enflammée avant de quitter l'endroit ou de se remettre au travail.2.The protection of forests against fire shall be carried out by the local organization for the protection of forests, the cost of which is to be borne entirely by the person for whom the operations are carried out.3.Before the said public works may be undertaken, the local organization for the protection of forests shall prepare, together with the person or company carrying out said operations or causing same to be carried out, an organized plan of protection and the ways and means to be used for the prevention, discovery and fighting of forest fires; this plan shall be submitted to the Honourable the Minister of Lands and Forests for approval, and the operations shall not be undertaken until a permit therefor shall have been issued by the Forest Protection Branch, upon the recommendation of the local organization for the protection of forests.This permit may be cancelled while the work is being performed, is said person or company carrying out said operations or causing same to be carried out, neglects or refuses to enforce, or oblige his entire staff to enforce the laws and regulations respecting the protection of forests against fires.4.An inspector, and assistant-inspectors if necessary, plus an adequate number of fire-rangers shall be hired by the said local organisation for the protection of forests, and they shall be appointed by the Honourable the Minister of Lands and Forests in order to ensure an effective supervision of operations from the point of view of protecting the forests against fires.5.In order to confer greater authority on said organization for the protection of forests, the salaries of said employees and any other expenditures incurred shall be paid .by said organization, free to be refunded montlily by the party for whom this work is being performed.6.The inspector or officer in charge of said protection, shall be entirely responsible for the protection of forests against fires, and shall have complete authority in the organizing of patrol rounds, managing of personnel entrusted with the carrying out of said work as well as that which concerns labour, supplies, equipment, etc., and the summoning of assistance in the event of the spreading of a fire.7.All fire-fighting equipment shall be supplied by the party for whom the operations are being carried out, or indirectly by the local organization for the protection of forests or directly by the party itself, and the inspector shall place said equipment in adequate localities in order to provide for all emergencies in case of forest fires.8.For proper indentification purposes, any person employed in such operations shall carry a bona fide travel permit or any other valid pass for working purposes only, and recognized by the Honourable the Minister of Lands and Forests as being the equivalent; said employees shall give a proper account of their comings and goings, when required to do so by a fire-ranger, constable or an officer of the peace.9.Smoking is prohibited while performing any work, or while travelling on foot, on horseback or in a motor vehicle or otherwise.However, smoking is permitted during recess periods in an appropriate place, insofar as all inflammable substances are extinguised before vacating the place or on resuming work. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 255 10° Pour faire des feux de cuisson, il faut: a) obtenir un permis de l'inspecteur ou d'un autre officier autorisé, lequel permis peut être annulé durant les périodes d'alerte; b) choisir un endroit propice, jamais sous un arbre et de préférence près d'un lac ou d'un cours d'eau; c) nettoyer l'endroit en enlevant du sol, dans un rayon de quatre (4) pieds, toute terre végétale, tous bois morts et toutes branches, broussaille et feuilles sèches; d) éteindre complètement le feu avant de quitter l'endroit.11° Il est interdit de faire des feux pour chasser les moustiques autrement que dnns un contenant métallique; tel contenant doit être placé en un endroit débarrassé de toute terre végétale, broussailles et débris ligneux, sur un rayon de quatre (4) pieds et le feu doit être complètement éteint avant de quitte/ les lieux.Pour faire de tels feux, un permis écrit doit être obtenu de l'inspecteur, et tel permis peut être annulé durant les périodes d'alerte.12° Aucun défriché ou déblayage ne peut être entrepris par des moyens mécaniques ou autres avant que les arbres aient été abattus et que les bois de valeur marchande ou commerciale aient été récupérés.13° Les travaux de brûlage pour fins de débarras et de nettoyage doivent être exécutés conformément aux lois et règlements régissant le brûlage des abatis et autres déchets, et sous la surveillance immédiate d'un garde-feu.14° Conformément à l'article 153/; de la Loi des terres et forêts, tous les débris de la forêt doivent être enlevés sur une distance de cinquante (50) pieds, autour de tous les établissements, bâtisses, constructions ou autres installations.15° Conformément à l'article 153a de la Loi des terres et forêts, tout établissement, habitation, bâtisse, construction ou autre installation doit être pourvu des appareils les plus perfectionnés et les plus efficaces pour prévenir l'échappement du feu et des étincelles et approuvés par l'organisation locale de protection des forêts.16° Tous les camps et bâtisses qui ne servent plus à l'exécution des travaux, doivent être enlevés ou brûlés avec l'autorisation écrite du garde-feu et sous la surveillance immédiate de ce dernier.17° En période d'alerte, on devra, à la demande de l'inspecteur ou du garde-feu, cesser de faire du feu pour quelque besoin que ce soit et se priver absolument de fumer en dehors des camps.18° Conformément à l'article lôSd de la Loi des terres et forêts, toute personne engagée pour travailler à la protection des forêts contre les incendies peut requérir les services de tout homme âgé d'au moins dix-huit ans et d'au plus cinquante-cinq ans, pour aider à combattre un incendie forestier.19° Tout employé qui découvre un incendie doit l'éteindre immédiatement et, au cas d'impossibilité, avertir en toute hâte le garde-feu le plus rapproché ou son contremaître.20° Conformément à l'article 156, il est défendu de détruire, endommager ou enlever toute affiche d'une organisation chargée de la protection des forêts contre le feu.21° La personne ou compagnie pour le compte de laquelle les-travaux sont exécutés, est responsable des dommages causés à la propriété de l'organisation locale de protection des forêts contre le feu, par elle-même, ses contracteurs ou ses employés; elle est également responsable des dommages causés et des frais d'extinction encourus\"par suite de tout incendie occasionné 10.Re: Fires for Cooking purposes: a) A permit shall be obtained from an inspector or any other officer authorized therefor, which permit may be cancelled during periods of emergency; /;) An appropriate place shall be selected; never under a tree, preferably near a \"lake or st ream ; r) Said place shall be cleared by removing from' the soil, within a radius of four (1) feet, all vegetable matter, dead wood, and all branches, brushwood and dry leaves; d) The fire shall be totally extinguished before vacating the place.11.It is prohibited to set any fires in order to drive flies away otherwise than in metal containers; which containers shall be placed in a spot claer of all vegetable matter, brushwood and woody debris, within a radius of four (4) feet, and the fires shall be entirely extinguished before vacating the place.In order to light said fires, a written permit shall be obtained from the inspector and the latter may be calccllcd during periods of emergency.12.No grubbing or clearing may be undertaken mechanically or otherwise, unless* the trees have been felled and the timber of market or commercial value shall have been recovered.* 13.Burning for clearing away purposes shall be carried out in accordance with the laws and regulations governing the burning of slash and other refuse, and thus, under the direct supervision of a fire-ranger.14.Pursuant to section 1536 of the lands and forests Act, forest debris shall be removed within a distance of fifty (50) feet all around any establishment, building, construction or other installation.15.Pursuant to section 153a of the lands and forests Act, any establishment, dwelling, building, construction or other installation shall be provided with the most improved and effective fire prevention equipment for the escape of fire and sparks, and shall be approved by the local organization for the protection of forests-.16.All camps and buildings no longer required for the operations being carried, shall be removed or burnt, with the written authorization of the fire-ranger ami under the direct supervision of the latter.17.During an emergency period, one shall, at the request of the inspector or fire-ranger, cease to make fires for any requirement whatsoever, and refrain from smoking outside camps.18.Pursuant to section \\~)3d of the lands and forests Act, any person engaged in work for the protection of forests against fire, may call upon any man of not less than eighteen nor over fifty-five years of age, to assist him in fighting a forest fire.19.Any employee who discovers a fire shall immediately extinguish it, and should it be impossible, he shall hasten to advise the nearest fire-ranger or his foreman.20.Pursuant to section 156, it is prohibited to destroy, damage or remove .any poster of an organization in charge of the protection of forests against fire.21.Any person or company for whom work is being performed, shall be liable for damages caused to the property of the local organization for the protection of forests against fire, whether caused by said person or company, contractors or employees thereof; the said person or company is equally liable for damages caused, or costs incurred following any fire resulting from his 256 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 8 par ses travaux et cela même si l'incendie set attribuahle au personnel employé à ces travaux.22° Toute infraction aux présents règlements, si aucune peine spéciale n'est prescrite, rend le contrevenant passible des peines prévues par l'article 153c de la Loi des terres et forêts.23° Tout employé trouvé coupable d'une infraction aux présents règlements doit être congédié immédiatement et l'employeur est tenu de coopérer avec l'organisation de protection des forêts pour appliquer les pénalités prévues dans chaque cas.24° Toute personne sous le coup d'une condamnation pour infraction aux présents règlements, perd le droit de pénétrer ou de demeurer en forêt durant la même année.Le présent arrêté ministériel abroge, à toute fin que ce soit, l'arrêté en conseil N° 498, en date du 15 mai 1951.L.DÉSILETS, 39079-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1216 Québec, le 15 décembre 1954.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil Concernant le brûlage des abatis et des débris forestiers.Attendu Qu'en vertu de l'article 124 de la Loi des terres et forêts il est obligatoire, entre le 1er avril et le 15 novembre, de se procurer au préalable un permis pour mettre le feu dans la-forêt ou à une distance de moins d'un mille de la forêt, à quelque tas de bois, de branchages ou de brouissailles, à quelque arbre, arbuste ou autre plante, à quelque terre légère ou terre noire, cà quelque tronc d'arbre, abatis ou autres bois abattus pour quelque fin que ce soit: Attendu Qu'en vertu des articles 125 et 128 de la dite loi, il est nécessaire de prendre des mesures de précaution particulières pour assurer la protection des forêts contre le feu ; II est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre des Terres et Forêts: Que le brûlage des abatis et autres déchets soit régi par les règlements suivant: 1° Les matières destinées au brûlage doivent être mises en tas ou en rangées, à une distance d'au moins cinquante (50) pieds de la forêt.Cet espace séparant l'abatis de la forêt doit être débarrassé de tout débris forestier pour constituer un bon coupe-feu.L'empilement des débris ne doit pas dépasser huit (8) pieds de hauteur et tous les arbres et chicots doivent y être abattus.Tous les chicots en forêt en bordure de l'abatis doivent également être abattus; 2° Le permis de brûlage est gratuit; il ne peut être obtenu que le jour même du brûlage et n'est valide que pour cette journée-là; il ne donne pas le droit d'allumer quand il vente fort ou lorsqu'il est à craindre que le brûlage ne provoque un incendie.Il peut être annulé en tout temps; 3° Le permis n'autorise pas à mettre le feu avant quatre (4) heures de l'après-midi (heure solaire) ; 4° Le.brûlage des abatis est toujours interdit le samedi ou la veille d'une fête obligatoire; or its operations, even if the fire is caused by the personnel hired for said operations.22.Any infringement of said regulations, if no special penalty is prescribed, renders the offender liable to the penalties under section 153c of the lands and forests Act.23.Any employee found guilty of an infringement of said regulations shall be fired immediately and the employer is bound to cooperate with the organization for the protection of forests, in applying the penalties provided therefor in each case.24.Any person under conviction for infringement of said regulations, forfeits his privilege of entering the forest and remaining therein, during the period of that year.This Order in Council repeals, for any purpose whatsoever, Order in Council No.498, dated May 15th, 1951.L.DÉSILETS, 39079 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1216 Quebec, December 15th, 1954.Present: The Lieutenant-Governor in Council Concerning the burning of slash and forest debris.Whereas under section 124 of the Lands and Forests Act, it is obligatory, between April 1st, and November 15th, to obtain first of all, a permit in order to set any fires in the forest or at a distance of one mile therefrom, to any pile of wood, branches or brushwood, or any tree or shrub, or other plant, or any black loam or light soil, or any tree trunk, slash or other timber felled for any purposes whatsoever.Whereas under sections 125 and 128 of the said Act, it is expedient that special precautionary measures be taken in order to ensure the protection of forests against fire; Consequently, it is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Lands and Forests; That the burning of slash and other refuse shall be governed by the following regulations: 1.\"Substances destined to be burnt shall be piled in heaps or rows, at a distance of at least fifty (50) feet from the forest.This space between the felling of trees and the forest shall be cleared of all forest debris in order that it may constitute an adequate fire-break.The piling up of debris shall not exceed eight (8) feet in height, and all trees and stumps shall be felled therein.All the stumps in the forest along the clearing space shall also be cut down; 2.Permits for burning purposes are free of charge; they may only be obtained the day on which the burning is to take place, and are valid for that day only; these permits do not allow the serring of fires when the wind is high or if it is feared that an outbreak may be caused therefrom.Said permits may be cancelled at any time; 3.Holders of permits are not allowed to set any fire before four (4) o'clock in the afternoon (Standard Time) ; 4.The burning of slash is always prohibited on Saturdays or on the eve of a feat of obligation; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.8 257 5° Le permissionnaire est tenu de rester sur les lieux jusqu'à ce que les feux soient complètement éteints et il doit procéder à l'extinction dès le lendemain matin qui suit la date du brûlage; 6° L'obtention d'un permis de brûlage ne libère pas le permissionnaire de ses responsabilités ordinaires, dans le cas où des déboursés ou dommages résultent de ce brûlage; 7° Toute infraction aux présents règlements rend le contrevenant passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins cinquante dollars et d'au plus deux cents dollars ou d'un emprisonnement d'au moins un mois et d'au plus six mois et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement d'au moins un mois et d'au plus six mois.Le présent arrêté ministériel abroge, à toute fin que ce soit, l'arrêté en conseil numéro 2094, du 21 août 1942.Greffier du Conseil Exécutif, 39079-o L.DÉSILETS.5.The holder of a permit is bound to remain on the premises until the fires are completely out and he shall proceed to extinguish said fires as early as the morning following date of said burning of slash or forest debris.6.The obtaining of a permit for burning purposes does not release the permit holder from his ordinary responsabilitics involving disbruse-ments or damages caused by said fires; 7.Any infringement of said regulations renders the guilty party liable, over and above costs, to a fine of not less than fifty or more than two hundred dollars, or to imprisonment for not less than one month or more than six months, and should he fail to pay the fine and costs, he shall be liable to imprisonment for at least one month and not more than six months.This Order in Council repeals for any purpose whatsoever, Order in Council number 2094, dated August 21st, 1942.L.DÉSILETS, 39079 Clerk of the Executive Council.Avis divers AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Syndicat Catholique des Employés de Magasins de Magog\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le trente décembre 1954.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Magog, dans le comté de Stanstead.Le Sous-secrétaire de la Province, 39072-o JEAN BRUCHÉSI.Miscellaneous Notices NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Syndicat Catholique des Employes de Magasins de Magog\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on December thirtieth, 1954.The principal place of business of the said professional syndicate is at Magog, in the county of Stanstead.JEAN BRUCHÉSI, 39072 Under Secretary of the Province.(P.G.5978-52) Lbs Entreprises de Terrazzo, Marbre et Tuile Ltée Règlement N° 6 concernant le nombre de directeurs de la Compagnie.Il est décrété: 1° Que le nombre des directeurs de la Compagnie soit, et il est par les présentes, diminué de cinq à quatre, de sorte que le conseil d'administration de la Compagnie soit dorénavant composé de quatre directeurs.2° Que tous règlements et résolutions incompatibles avec le présent règlement sont amendés, revisés et modifiés pour donner plein effet au présent règlement.3° Qu'une assemblée générale des actionnaires soit convoquée aussitôt que possible après la publication du présent règlement, dans la Gazette officielle de Québec, au lieu, date et heure que déterminera le président, pour procéder à une élection des directeurs.Passé ce dix-septième jour de décembre 1954.(Sceau) (Signé) Le Président, JEAN BÉDARD.(Signé) Le Secrétaire, 39077-o ARTHUR FAUCHER.(A.G.5978-52) Les Entreprises de Terrazzo, Mardre et Tuile Ltée By-law No.6 concerning the number of directors of the Company.Be it enacted: 1.That the number of directors of the Company be, and is hereby decreased from five to four, in order that the Company's Board of Directors shall hereafter be composed of four Directors.2.That all by-laws and resolutions inconsistent herewith are hereby amended, revised and modified in order to give effect to this by-law.3.That a general meeting of shareholders be called as soon as possible following the publication of this by-law, in the Quebec Official Gazette, at the place, date and time which the President shall fix, for the purposes of electing the directors.Passed this seventeenth day of December 1954.(Seal) (Signed) JEAN BÉDARD, President.(Signed) ARTHUR FAUCHER, 39077*;.Secretary. 258 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 8 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fcndation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire du Petit Séminaire de St-Gcorges, Beauce\", en date du 10 décembre 1954, dont le siège social est situé à Saint-Georges (au Petit Séminaire), dans le comté de Beauce, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné a»i bureau du Secrétaire de la Province le seize décembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 39070-o JEAN BRUCHÉSI.(P.G.11537-54) Pointe Claire Civic Action League Extrait des règlements de la corporation ci-dessus nommée concernant une augmentation dans son bureau de direction de cinq (5) à sept \"Article 8: Bureau de direction \u2014 Le bureau de direction sera formé: (1) Le Président, les Vice-présidents, le Secrétaire, le Trésorier et deux autres Directeurs, faisant un total de sept directeurs devant être élus à l'assemblée générale biennale, et dont le quorum sera de cinq directeurs.\" Certifié vraie copie: Montréal, 26 octobre 1954.(Signé) Le Secrétaire, 39078 A.JANUSITIS.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire du Petit Séminaire de St-Geor-ges, Beauce\", under date of December 10th, 1954, whereof the hcae office is at Saint-Georges (au Petit Séminaire), in the county of Beauce, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this sixteenth day of December, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 39076 Under Secretary of the Province.(A.G.11537-54) Pointe Claire \"Civic Action League Extract from the By-laws of the above named Corporation concerning an increase in the directorate thereof from five (5) to seven (7) : \"Article 8: Board of Directors \u2014 The Board of Directors shall consist of: (1) The President, the Vice-Presidents, the Secretary, the Treasurer and two other Directors, making a total of seven Directors to be elected at the Biennial General Meeting, with a quorum consisting of five Directors.\" Certified true copy: Montreal, October 26th, 1954.(Signed) A.JANUSITIS, 39078-o Secretary.(P.G.4776-52) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général,, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le treize janvier 1955, le règlement N° IV de la corporation \"Hôpital Comtois, Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le quatorze janvier 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39091-o JEAN BRUCHÉSI.(A.G.4776-52) .Notice is given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary approved,' on January thirteenth 1955, By-law No.IV of the corporation \"Hôpital Comtois, Inc.\", and such, pursuant to the provisions of section 225a of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary on January fourteenth 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39091 Under Secretary of the Province.(P.G.1965-48) Ormstown War Memorial Community Centre Inc.Lors d'une assemblée générale des membres de \"Ormstown War Memorial Community Centre Inc.\", tenue le 29 novembre 1954, à Ormstown, Québec, l'amendement suivant au règlement IV a été apporté: \"Il a *té proposé par B.L.McGerrigle, secondé par J.D.Bryson que le nombre des directeurs de Ormstown War Memorial Community Centre Inc.soit augmenté de neuf à onze.Adopté.\" Vraie copie certifiée.Le Secrétaire-trésorier, 39098 H.F.ROSS.(P.G.9383-52) Trans-Canada Film Distributors Corp.Règlement N° 24 \"1° Le nombre des directeurs de la compagnie est réduit de six (6) à quatre (4), de mariière que le bureau de direction de la compagnie soit composé dorénavant de quatre (4) directeurs.2° Deux (2) directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.(A.G.1965-48) Ormstown War Memorial Community Centre Inc.\\ At a General Meeting of the members of the \"Ormstown War Memorial Community Centre Inc.\", held November 29th, 1954, at Ormstown, Quebec, the following amendment to By-law IV was made : \"Moved by B.L.McGerrigle, seconded by J.D.Bryson, that the number of directors of the Ormstown War Memorial Community Centre Inc.be increased from nine to eleven.Carried.\" Certified true copy.H.F.ROSS, 39098-o Secretary-Treasurer.(A.G.9383-52) Trans-Canada Film Distributors Corp.By-law No.24 \"1.The number of Directors of the company is reduced from six (6) to four (4) in number so that the Board of Directors of the company shall hereafter be composed of four (4) Directors.2.Two (2) Directors shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.8 259 3° Tous les règlements, resolutions et procé- 3.All prior By-laws, resolutions and proceed- dures antérieurs de la compagnie incompatibles higs of the company inconsistent herewith are à icelui sont, par les présentes, amendés; modi- nereby amended, modified and revised in order fiés et revisés pour donner effet à ce règlement.\" to give effect to this By-law.\" Certifié vraie copie.Certified true copy.Le Secrétaire, (Sgd) W.ELMAN, 39109 (Signé) W.ELMAN.39109-o Secretary.(P.G.47657-53) Brinton Realty Corp.Règlement N° 27 (A.G.47657-53) Brinton Realty Corp.\"Sur proposition dûment faite et secondée, la résolution suivante a été adoptée à l'unanimité: Qu'il soit résolu : Que le règlement N° 27 soit et il est, présentement décrété en réduisant le nombre des directeurs de la compagnie de quatre directeurs à trois directeurs.\" Le Président, 39108 JULES LABERGE.39108-o By-law No.27 \"Upon motion duly made and seconded} the following Resolution was unanimously adopted: Be it resolved : That By-law No.27 be and is herewith enacted reducing the number of Directors of the company from four directors to three directors: JULES LABERGE, President.(P.G.10843-54) Les Entreprises Pyramides Limitée Règlement N° 17 \"1.A ce que le nombre des directeurs de la compagnie soit par les présentes augmenté de trois à cinq et fixer le bureau des directeurs de la compagnie de cinq directeurs; 2° Trois directeurs consistera le quorum pour toute assemblée du bureau des directeurs; 3° Toute résolution, règlement et procédure de la compagnie antérieures aux présentes sont par les présentes amendés, modifiés et revisés pour donner effet au présent règlement.Décrété ce 25 août 1954.Le Président, C.LA VALLÉE.Le Secrétaire, 39110-o YVON PERRAS.(A.G.10843-54) Les Entreprises Pyramides Limitée By-law No.17 \"1.That the number of the directors of the company be^ by these presents, increased from three to five and establish the board of directors of the company of five directors; 2.The quorum for all meeting of the board of directors will be composed of three directors; 3.All resolution, by-law and procedure of the company, previous to these presents, are by these presents amended, modified and revised to give effect to the present by-law.\" Enacted this 25th, day of August, 1954.C.LA VALLÉE, President.YVON PERRAS, 39110-o Secretary.Chartes \u2014 Abandon de Charters \u2014 Surrender of Randall Realties Inc.Avis est, par les présentes, donné que \"Randall Realties Inc.\", une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège, social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 15e jour de décembre 1954.Le Secrétaire, 39064 ANNA METH.(P.G.10089-55) Crabtree & Company Ltd.Selon les dispositions de la loi des compagnies de Québec, la Crabtree & Company Ltd., tient à donner avis par la présente qu'elle fera application devant le procureur général afin d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, le 7 janvier, 1955.Le Président, 39086-o HERBERT K.CRABTREE.Randall Realties Inc.Notice is hereby given that \"Randall Realties Inc.\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal this 15th day of December 1954.ANNA METH, 39064-o Secretary.(A.G.10089-55) Crabtree & Company Ltd.Under the provisions of the Quebec Companies' Act, Crabtree & Company Ltd., hereby gives notice that it will make application to the Attorney General for leave to surrender its Charter.* Dated at Montreal, Januarv 7th, 1955.HERBERT K.CRABTREE, 39086-o President. 260 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1965, Tome 87, N° 3 AVIS W.B.Realty Company Avis est par les présentes donné que \"W.B.Realty Co.\", une corporation constituée sous la Loi des Compagnies de Québec et ayant son siège social dans la Cité de Québec, fera une demande au Procureur général de la Province de Québec, pour lui permettre d'abandonner sa charte sous l'empire de la Loi des Compagnies de Québec.Daté à Québec, ce lie jour de janvier 1955.La Secrétaire, 39065-o SIMONE DROLET.NOTICE W.B.Realty Company Notice is hereby given that the \"W.B.Realty Co.\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Quebec, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Quebec, this llth day of January, 1955.SIMONE DROLET, 39065-o Secretary.Bramhorn Inc.Avis est par les présentes donné que \"Bramhorn Inc.\", a l'intention de demander au Procureur Général de la Province de Québec la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 14 janvier 1955.La Secrétaire, 39087-o GERTRUDE HERSHORN.Bramhorn Inc.Notice is hereby given under the Quebec Companies' Act and amendments that \"Bramhorn Inc.\" intends to make application to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.Montreal, January 14th, 1955.GERTRUDE HERSHORN, 390S7-o \u2022 Secretary.Compagnie autorisée à faire des affaires (Sec.P.3107-54) Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Friedrich Refrigerators Incorporated\", été a\\itoriséc à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères, S.R.Q.1941, chapitre 279.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province est à 2000 édifice Aldred, 507 Place d'Armes, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal aux fins de recevoir les assignations dans toutes procédures prises contre elle, est M.W.H.Laidley, de ladite cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 18e jour de janvier 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39062 JEAN BRUCHÉSI.Company Licensed to do Business (P.Sec.3107.54) Notice is hereby given that \"Friedrich Refrigerators Incorporated\", has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provision of the Extra-Provincial Companies' Act, R.S.Q.1941, chapter 279.The principal office of the said company in the Province is 2000 Aldred Building, 507 Place d'Armes, in the city and judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.W.H.Laidly, of the said city of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 18th day of January, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39062-o Under Secretary of the Province, Compagnies dissoutes (P.G.12008-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Karrys' Recreation Academy, Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 2 juillet 1954.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze janvier 1955, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit janvier 1955.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.Companies Dissolved (A.G.12008-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276,- R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Karrys' Recreation Academy, Ltd.\", incorporated by letters patend dated July 12th, 1954.Notice is also given that from and after January fifteenth 1955, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this January eighteenth, 1955.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87?No.3 261 (P.G.12916-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \" Mac Holdings Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 26 février 1954.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze janvier 1955, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit janvier 1955.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(P.G.12439-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Page Construction (Québec) Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 5 avril 1939.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze janvier 1955, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit janvier 1955.L'Assistant-procureur général, 39062-o \u2022 C.E.CANTIN.(P.G.12379-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"The Acme Realty Co.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 15 avril 1952.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze janvier 1955, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit janvier 1955.L'Assistant-procureur général, 39062-o C.E.CANTIN.(A.G.12916-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Mac Holdings Inc.\", incorporated by letters patent dated February 26th, 1954.Notice is also given that from and after January fifteenth 1955, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of January, 1955.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12439-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Page Construction (Québec) Limitée\", incorporated by letters patent date April 5th, 1939.Notice is also given that from and after, January fifteenth 1955, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this January eighteenth, 1955.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.(A.G.12379-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"The Acme Realty Co.\", incorporated by letters patent dated April 15th, 1952.Notice is also given that from and after January fifteenth 1955, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this January eighteenth, 1955.C.E.CANTIN, 39062 Deputy Attorney General.Curatelle publique Canada \u2014 Province de Québec District d'Abitibi Succession vacante de Henri Doucet, en son vivant de Dubuisson, (Aibitibi Est).Le soussigné donne avis que cette succession a été déclarée vacante en vertu d'un jugement rendu le 3 juin 1954 par un juge de la cour supérieure siégeant à Amos dans le district d'Abitibi que, sous l'autorité de la loi de la curatelle publique (9 Geo.VI, c.62), il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.LE CURATEUR PUBLIC, 187, rue Sainte-Catherine (Ouest), 39071-o Montréal 18.Public Curatorship Canada \u2014 Province of Quebec District of Abitibi Vacant estate of Henri Doucet, in his lifetime of Dubuisson, (Aibitibi-East).The undersigned gives notice that this estate has been declared vacant by virtue of a judgment rendered on June 3rd, 1954 by a Judge of the Superior Court sitting at Amos in the district of Abitibi, that under the authority of the Public Curatorship Act (9 Geo.VI, Chap.62), he is Curator ex officio for this estate and that receive, at the address hercbelow, payment of any debt towards the estate and the proof of any claim against it.PUBLIC CURATOR, 187, Sainte-Catherine Street (West), 39071 Montreal 18. 262 QAZE9TE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 Demandes à la Législature AVI* PUBLIC Avis public est, par les présentes, donné que la ville de Dorval, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, la Loi 14 George VI, chapitre 120, en sus des matières décrites à l'avis du 22 novembre 1954, sur les matières suivantes: annexion du territoire de la corporation municipale de la paroisse de Côte de Liesse; et pour autres fins.Montréal, le 22 décembre 1954.Les Procureurs de la Ville de Dorval, LACROIX, VIAU & POUPART.38917-53-4-0 Applications to Legislature PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the town of Dorval will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter, the Act 14 George VI, chapter 120, in addition to the purposes described in the notice of November 22th, 1954, for the following purposes: annexation of the territory of the municipal corporation of the parish of Côte de Liesse; and for other purposes.Montreal, December 22nd, 1954.LACROIX, VIAU & POUPART, Attorneys for the Town of Dorval.38917-53-4-0 AVIS PUBLIC Avis public est, par les présentes, donné que la ville de Pointe-Claire s'adressera si la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi, amendant sa charte, la loi 1 George V, chapitre 71, en sus des matières décrites à l'avis du 3 novembre 1954, sur les matières suivantes: imposer une taxe de vente de 2% pour fins municipales; et pour autres fins.Montréal, le 23 décembre 1954.Les Procureurs de la Ville de Pointe-Claire, LACROIX, VIAU & POUPART.38918-53-4-0 Avis public est par les présentes donné que l'Honorable P.R.DuTremblay, avocat, membre du Sénat du Canada et du Conseil Législatif de la Province de Québec, des cité et district de Montréal, Lucien Dansereau, ingénieur civil et Gilles Bcrthiaume, journaliste, tous deux de la cité d'Outremont, district de Montréal, Angelina Berthiaume, épouse dudit l'Honorable P.R.DuTremblay et par ce dernier dûment autorisée, Anna Berthiaume, fille majeure, des cité et district de Québec, Helmina Berthiaume, de Rome, Italie, veuve de feu Joseph Rivet et Marie Berthiaume, épouse de Gabriel Lord, dentiste, de la cité d'Outremont, district de Montréal et par ce dernier dûment autorisée s'adresseront à la Législature de la Province de Québec à sa présente session pour demander l'adoption d'une loi relative au testament de feu l'Honorable Tréfilé Berthiaume fait en date du 23 juin 1913 et à la donation fiduciaire faite par ce dernier en date du 26 décembre 1914, aux fins de confirmer la nomination et l'administration des fiduciaires en vertu de ces deux actes, de régler le mode de leur remplacement et de leur destitution et de mettre fin en conséquence à certaines instances judiciaires.Montréal, 5 janvier 1955.' Le Procureur des pétitionnaires, GASTON POULIOT.159 ouest, rue Craig, 38958-1-4-0 Montréal.AVIS LÉGAL L'Association des courtiers d'assurance de la province de Québec donne avis publiquement qu'elle s'adressera à la Législature de la province PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the town of Pointe-Claire will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter, the Act 1 George V, chapter 71, in addition to the purposes described in the notice of November 3rd, 1954, for the following purposes: to impose a 2% tax for municipal purposes; and for other purposes.Montreal, December 23rd, 1954.LACROIX, VIAU & POUPART, Attorneys for the Town of Pointe-Claire.38918-53-4-0 Public notice is hereby given that the Honourable P.It.DuTremblay, member of the Senate of Canada and of the Legislative Council of the Province of Quebec, of the city and district of Montreal, Lucien Dansereau, civil engineer and Gilles Berthiaume, journalist,, both of the city of Outremont, district of Montreal, Angelina Berthiaume, wife of the said Honourable P.R.DuTremblay and by him duly authorized, Anna Berthiaume, spinster, of the city and district of Quebec, Helmina Berthiaume, of Rome, Italy, widow of the late Joseph Rivet, and Marie Berthiaume, wife of Gabriel Lord, dentist, of the city of Outremont, district of Montreal and by him duly authorized, will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its current session to request the enactment of a law with respect to the Will of the late the Honourable Tréfilé Bcrthiaume dated -23rd June, 1913, and to the donation in trust made by the said Honourable Tréfilé Berthiaume on December 26th, 1914, for the purpose of confirming the appointment and the administration of the trustees under the said two documents, of settling the method of replacement and disqualification of such trustees and consequently of terminating certain judicial proceedings.Montreal, this 5th dav of January, 1955.GASTON POULIOT, Attorney for the petitioners.159 Craig Street West, 38958-1-4-0 Montréal.LEGAL NOTICE Notice is hereby given that the Insurance Brokers' Association of the Province of Quebec will apply to the Legislature of the Province of Que- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 263 de Québec à la présente session, pour obtenir des modifications à sa charte, ayant pour objet d'organiser la profession de courtier d'assurance en un corps professionnel sous le nom de \"Corporation des courtiers d'assurance de la province de Québec'' et groupant toutes les personnes qui agissent dans la province comme intermédiaires dans les affaires d'assurance, sans être liées avec un assureur par un contrat les obligeant à ne négocier des affaires d'assurance que pour le compte de cet assureur, étant exclues, cependant, les personnes qui ne négocient que l'assurance-vic et les employés salariés d'une compagnie d'assurance qui ne reçoivent pas de commission; de prévoir l'admission dans la corporation, sans examen, des personnes désirant pratiquer la profession de courtier pour des affaires d'assurance autre que de la personne et ayant obtenu dans l'année précédant la sanction de la loi proposée une licence d'agent du surintendant des assurances de la province de Québec; de diviser les membres de la profession en groupes distincts, le premier comprenant les courtiers d'assurance agréés, et le second les courtiers d'assurance, les courtiers agréés, devant mériter leur titre en subissant avec succès des examens organisés par la corporation; de déterminer les privilèges et les obligations de chaque groupe; d'édicter des peines contre les personnes qui pratiquent illégalement la profession de courtier ou qui usurpent le titre de courtier d'assurance agréé ou de courtier d'assurance; d'organiser l'administration des affaires de la corporation dans le meilleur intérêt de la profession et du public en général.Avocats de l'Association des Courtiers d'assurance de la province de Québec, Noël et Rioux, 27 rue Buade, Québec.3S979-2-4-0 NOËL & RIOUX.AVIS PUBLIC Avis public est présentement donné qu'Irving-Louis Paul, rentier, ci-devant de Montréal, résidant actuellement à Miami-Beach, dans l'État de Floride, Sydney Paul, administrateur, de Flushing, Barnet Putterman, comptable, tous deux des ville et Etat de New York, et Samuel Paul, administrateur de la _ville de Kansas, État de Missouri, tous des États-Unis d'Amérique, pétitionneront les Corps législatifs de la province de Québec, à leur présente session, pour l'adoption d'une loi validant un accord intervenu le 22 décembre 1954 entre les pétitionnaires, l'épouse dudit Irving-Louis Paul (née Marlcau) et les bénéficiaires et fiduciaires de celui-ci, par-devant Me J.-Barrie Campbell.Montréal, le 31 décembre 1954.Les Avocats des pétitionnaires, VICTOR PAGER et LOUIS-JOSEPH 38953-1-4-0 DE LA DURANTAYE AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la Corporation de l'École polytechnique, corps politique légalement constitué ayant son siège social à Montréal, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour demander l'adoption d'une loi aux fins de refondre sa charte, la loi 57 Victoria, chapitre 23 et amendements, et particulièrement de modifier sa composition et ses pouvoirs.Montréal, le 11 janvier 1955.Le Procureur de la pétitionnaire, 39057-2-4-o GASTON POULIOT.bec, at its present session, to obtain some amendments to its charter, with the object of organizing the profession of insurance broker into a profes-sionnal body, under the name of the \"Corporation of Insurance Brokers of the Province of Quebec\", and grouping all the persons who act in the Province as intermediaries in insurance transactions without being bound towards an insurer by a contract obliging them to ncgociate insurance transactions for that insurer only, excluding however persons who ncgociate life insurance only and the salaried employees of an insurance company who do not receive a commission; of providing for the admission in the corporation, without examination, of persons who desire to practice the profession of broker for insurance other than of the person and who have'obtained in the year previous to the sanction of the proposed law, an agent's licence from the Superintendent of Insurance of the Province of Quebec; of dividing the members of the profession into distinct groups, the first one including the Chartered Insurance Brokers and the second one the Insurance Brokers, the Chartered Brokers having to earn their title by passing, with success, examinations organized by the corporation; of determining the privileges and obligations of each group; of inflicting penalties against persons who practice illegally the profession of broker or who usurp the title of Chartered Insurance Broker or of Insurance Broker; of organizing the administration of the affairs of the corporation in the best interest of the profession and of the public in general.Attorneys of the Insurance Brokers' Association of the Province of Quebec, Noel and Rioux, 27 Buade street, Quebec City.3S979-2-4-0 NOËL & RIOUX.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that Irving-Louis Paul, gentleman, formerly of the city of Montreal, now residing at Miami Beach, in the State of Florida, Sydney Paul, business executive, of Flushing, Barnet Putterman, accountant, both of the city and State of New-York, and Samuel Paul, business executive, of the city of Kansas in the Slate of Missouri, all of the United States of America, will petition the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an Act validating an agreement passed on the 22nd of December 1954, between them, the wife of the said Irving-Louis Paul (née Marlcau) and his beneficiaries and trustees, before Me J.-Barrie Campbell.Montreal, December 31st, 1954.VICTOR PAGER and LOUIS-JOSEPH DE LA DURANTAYE, 38953-1-4-0 Attorneys for the petitioners.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that \"La Corporation de l'Ecole polytechnique\", a body politic duly incorporated and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its present session, for the passing of an act to revise its charter, 57 Victoria, chapter 23 and amendments, and in particular to modify its composition and powers.Montreal, January llth 1955.GASTON POULIOT, 39057-2-4-0 Attorney for the petitioner. 264 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que Luc Prud'homme senior, gentilhomme, du village de Côte St-Luc, Luc Prud'homme junior, cultivateur, du même lieu, Dame Juliette Prud'homme, de la cité de Montréal, veuve d'Alphonse Cardinal en son vivant gentilhomme de la cité de Montréal, Dame Marie Prud'homme, épouse contractuellement séparée de biens de Lucien de Repentigny, jardinier, de la ville de Montreal-West, de ce dernier dûment autorisée.Dame Antoinette Prud'homme, épouse contractuellement séparée de biens de Lionel de Repentigny, employé civil de la ville de St-Laurent, de ce dernier dûment autorisée, Hector Prud'homme, médecin, de la cité de Montréal, et ledit Lucien de Repentigny en sa qualité d'administrateur et d'exécuteur testamentaire de la succession de Joseph Prud'homme, demanderont à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, la passation d'une loi spéciale aux fins de faire confirmer leur droit de vendre et autrement aliéner la propriété immobilière composée de diverses parties du lot de terre connu et désigné comme étant le numéro quatre-vingt-quinze (95) des plan et livre de renvoi officiels de la Municipalité de la paroisse de Montréal avec la bâtisses dessus érigées, ladite propriété immobilière plus amplement décrite dans l'acte de vente consenti à Saul Kaplan et Norman Holdings Corporation par les requérants devant Me Barnet Buckman, notaire, le 29 décembre 1952, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le N° 992,430, de faire disparaître tous doutes qui pourraient exister quant au droit des requérants de vendre et aliéner définitivement la susdite propriété immobilière, de confirmer, ratifier, valider et déclarer définitive l'aliénation de la susdite propriété immobilière par les requérants par et en vertu de l'acte de vente précité, de confirmer, ratifier et valider les aliénations subséquentes à ce dit acte de vente, et autres fins nécessaires ou utiles.Montréal, 7 janvier 1955.Les Procureurs des Requérants, DUSSAULT, DUSSAULT 39020-2-4-o & VADBONCOEUR.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la cité de Drummondville s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, le Loi 2 George VI (1938) chapitre 113 et les lois qui la modifient, (spécialement 3 George VI (1939) Chapitre III, articles 48 et 49) dans le but d'amender sa charte dans le sens suivant: 1° Prolonger de deux à trois ans le terme du maire et des échévins; 2° D'autoriser la cité de Drummondville à exproprier la Southern Canada Power; 3° D'accorder une exemption de taxes partielle à L'Amctex Limited de Drummondville.Drummondville, 17 janvier 1955.Le Procureur de la cité de Drummondville, 39089-3-4-o RENÉ MARCEAU.AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que Le Palais du Commerce Incorporé (Shôw-Mart Incorporated), s'adressera à la Législature de la PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that Luc Prud'homme senior, gentleman, of the village of Côte St.Luc, Luc Prud'homme junior, fariner, of the same place Dame Juliette Prud'homme, of the city of Montreal, widow of Alphonse Cardinal in his lifetime gentleman of the city of Montreal, Dame Marie Prud'homme, wife contractually separate as to property of Lucien de Repentigny, gardener of the town of Montreal-West, by the latter duly authorized, Dame Antoinette Prud'homme wife contractually separate as to property of Lionel de Repentigny, civil employee, of the town of St.Laurent, by the latter duly authorized, Hector Prud'homme physician, of the city of Montreal and the said Lucien de Repentigny, in his quality of administrator and testamentary executor of the estate of Joseph Prud'homme, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at tis present session for the passing of a special Act for the purpose of confirming their right to sell and otherwise alienate the immovable property composed of several parts of the lot of land known and designated as number ninety-five (95) on the official plan and book of reference for the Municipality of the parish of Montreal with the buildings thereon erected, the said immovable property being more fully described in the deed of sale from the Petitioners to Saul Kaplan and Norman Holdings Corporation, passed before Mtre.Barnet Buckman, Notary, on December 29th, 1952, registered in the Registry Office for the registration division of Montreal under No.992,430, to resolve any doubts as to the right of the petitioners to sell and alienate definitively the said immovable property, to confirm, ratify, validate and declare definitive the alienation of the said immovable property by the petitioners by and in virtue of the aforesaid deed of sale, to ratify and validate the alienations made subsequently to the said deed of sale, and other necessary or uscfull purposes.Montreal, January 7th, 1955.DUSSAULT, DUSSAULT, & VADBONCOEUR, 39020-2-4-o Attorneys for the petitioners.' PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the city of Drummondville will address the Provincial Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for adoption of a law amending its chapter, the law 2 George VI (1938) chapter 113 and the laws amending it, (specially 3 George VI (1939) chapter III, articles 48 and 49) so that the charter be amended as follows: 1.Extend from two to three years the term of office of the mayor and the alderman; 2.Authorize the city of Drummondville to expropriate the Southern Canada Power; 3.To grant a partial exemption of taxes to the Ametex Limited of Drummondville; Durmmondville, January 17th, 1955.RENÉ MARCEAU, Attorney for the city of 39089-3-4-o Drummondville.PUBLIC NOTICE &*» \u2014 Public notice is hereby given that Le Palais du Commerce Incorporé (Show-Mart Incorporated), will apply to the Legislature of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.S 265 Province de Quebec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant le projet de loi à être présenté par la cité de Montréal, aux fins de ratifier un projet d'acte de vente à intervenir entre la cité de Montréal et Le Palais du Commerce Incorporé, tel qu'autorisé par une résolution du Comité Exécutif de la cité de Montréal en date du 28 mai 1954 et confirmé par le Conseil Municipal de ladite cité, en date du 2 juin 1954; le tout, pertinent à un terrain situé entre les rues Ontario et Démontigny, la ruelle Savoie et la rue Berri.Montréal, le 17 janvier 1955.Les Procureurs de Le Palais du Commerce Incorporé, 39090-3-4-o LACROIX, VIAUX & POUPART.Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal AVIS Avis est par les présentes donné que Joseph Duhamel et René Duhamel, tous deux contrac-teurs de la cité de Montréal et y faisant affaires sous les nom et raisons sociale de \"Duhamel & Fils Enrg.\", feront une demande à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, aux fins «le faire adopter une loi pour déclarer les propriétés suivantes: 1° Certains lots vacants ayant front sur la rue St-Zotique, à Montréal, et connus et désignés sous les numéros sept cent dix-neuf, huit cent, huit cent six, huit cent quatre-vingt-six, neuf cent soixante et neuf cent soixante-six de la subdivision du lot originaire numéro cent quatre-vingt-neuf (189- 719, 800, 806, 886, 960, 966) aux plan et livre de renvoi officiels du village incorporé de la Côte de la Visitation; 2° Certains lots vacants ayant front sur la rue St-Zotique, à Montréal, et connus et désignés sous les numéros mille soixante-neuf et mille soixante-treize de la subdivision du lot originaire numéro cent quatre-vingt-huit (188, 1069, 1073).aux plan et livre de renvoi officiels du village incorporé de la Côte de la Visitation; 3° Un lot de terre sis à l'angle sud-ouest de la rue St-Zotique et de la 36e avenue, dans le quartier Rosemont, dans la cité de Montréal, et connu et désigné sous le numéro six cent quarante-quatre de la subdivision du lot originaire numéro cent quatre-vingt-neuf (189, 644) aux plans et livre de renvoi officiels du village incorporé de la Côte de la Visitation; non affectées d'une servitude, par suite de la clause ci-après qui apparaît dans les titres aux-dites propriétés mentionnées ci-haut: Ail buildings erected on said lots shall be built at least ten feet back from the line of the streets and any stable or outhouses at least 60 feet from street line.A servitude is hereby expressly stipulated forever on said lots hereby sold for each of the conditions in above clauses 2, 3 and 4 in favor of Vendor and assigns as owners of the adjoining properties or of properties in the Neighbourhood.Montréal, ce dix-sept janvier mil neuf cent cinquante-cinq (1955).Province of Quebec, at its present session, for the adoption of a law amending the proposed law to be presented by the city of Montreal, to ratify an agreement of sale to intervene between the city of Montreal and Le Palais du Commerce Incorporé, ;is duly authorized by a resolution of the Executive Committee of the city of Montreal dated the 28th day of May 1954 and ratified by the Municipal Council of said city on the 2nd day of June 1954, in relation to a lot situated between Ontario and Démontigny Streets, Savoie Lane and Berri Street.Montreal, January 17th, 1955.LACROIX, VIAU & POUPART, Attorneys for Le Palais, 39090-3-4-o du Commerce Incorporé.Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal NOTICE Notice is hereby given that Joseph Duhamel and René Duhamel, both contractors of the city of Montreal, carrying on business threin under the name and style of \"Duhamel & Fils Enrg.\", shall apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an Act, in order that the following properties: 1.Certain vacant lots fronting on St.Zotique Street, at Montreal, and known and designated under numbers seven hundred and nineteen, eight hundred, eight hundred and six, eight hundred and eighty-six, nine hundred and sixty-nine and nine hundred and .sixty-six of the subdivision of original lot number one hundred and eighty-nine (189, 719, 800, 806, 8S6, 960, 966) on the official plan and book of reference of the incorporated village of La Côte de la Visitation ; 2.Certain vacant lot fronting on St.Zotique Street, at Montreal, and known and designated under numbers one thousand and sixty-nine, one thousand and seventy-three of the subdivision of original lot number one hundred and eighty-eight (188, 1069, 1073), on the official plan and book of reference of the incorporated village of Côte de la Visitation; 3.A lot of land situated at the southwesterly angle of St.Zotique Street, and 36th.Avenue, in Rosemount, Ward in the city of Montreal, and known and designated under number six hundred and forty-four of the subdivision of original lot number one hundred and eighty-nine (189, 644) on the official plan and book of reference of the incorporated village of Côte de la Visitation; shall be declared unaffected by servitude, in accordance with the clause hereinunder, which clause appears in the titles of the said properties mentioned hereinabove : All buildings erected on said lots shall be built at least ten feet back from the line of the streets and any stable or outhouses at least 60 feet from street line.A servitude is hereby expressly stipulated forever on said lots hereby sold for each of the conditions in above clauses 2, 3 and 4 in favor of Vendor and assigns as owners of the adjoining properties or of properties in the Neighbourhood.Montreal, this seventeenth day of January, one thousand nine hundred and fifty-five (1955).Le Procureur des requérants, PHILIPPE FERLAND, 39104-3-4-o PHILIPPE FERLAND.39104-3-4 Attorney for the petitioners. 266 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 Département de l'Agriculture Industrie Laitière Commission de l'Industrie Laitière de la Province de Québec Ordonnance N° 7-55 Extrait des procès-verbaux des séances de la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec.Séance du jeudi.13 janvier 1955, tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à Montréal, à 10 heures de l'avant-midi.Présents: MM.Omer-E.Milol,.président, Joseph Hébert.Adrien Angers, .1.-Albert Char-trand, Walter 1).Lowe, commissaires, Alphonse Savoie, secrétaire, C.-A.Gamâche, C.R., conseiller juridique.La Commission décrète ce qui suit: 1° La présente ordonnance s'applique à toute personne qui, directement ou indirectement, vend ou livre du lait dans les limites de la région de Rivière-du-Loup.2° La région de Rivière-du-Loup comprend la cité de Rivière-du-Loup et le village de l'Isle Verte.3° Tout marchand de lait doit payer directement à ses fournisseurs-producteurs pour chaque cent livres de lait qu'il reçoit de ceux-ci, $4.45 net, F.A.B.la place d'affaires dudit marchand, et, à même cette somme, payer à la ( !om-mission de l'Industrie Laitière de la province de Québec un demi-cent par cent livres de lait ainsi reçu.4° Sauf les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, nul ne peut, dans tes limites de la région de Rivière^lu-Loup, offrir, vendre ou livrer du lait à des prix inférieurs à 11 cents la chopinc et 1!) cents la pinte.5° Nul ne peut, dans les limites de la région de Rivière-du-Loup, offrir, vendre ou livrer du lait à une épicerie, à un hôtel, à un restaurant, à un marchand ou à tout autre établissement de commerce à des prix inférieurs à (5 cents le de-miard, 10 cents la chopine et 17K» cents la pinte.6° Nul marchand de lait ne peut vendre, offrir ou livrer du lait aux distributeurs de produits laitiers à un prix inférieur à 60 cents le gallon.- 7° Nul marchand de lait, société cooperative ou syndicat coopératif ne peut vendre, offrir ou livrer du lait en bidon, destiné, aux hôpitaux et aux institutions de charité, à un prix inférieur à 60 cents le gallon.8° Nul ne peut vendre, offrir ou livrer du lait en bouteille d'un demiard, pour distribution aux écoliers, à un prix inférieur à 5 cents le demiard.La présente ordonnance annule 1 ordonnance N° 7-54 publiée dans la Gazelle officielle de Québec du 16 janvier 1954, et entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec., Signé: Omer-E.Milot, president, Adrien Angers, commissaire.Joseph Hébert, commissaire, J.-A.Chartrand, commissaire, Walter D.Lowe, commissaire.Certifié: Alphonse Savoie, secrétaire, 39085-o Department of Agriculture Dairy Industry Dairy Industry Commission of the Province of Quebec Order No.7-55 Excerpts from the proceedings of the meetings of the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec.v Meeting of Thursday, January 13th, 1955, held in the ofiice of the Dairy Industry Commission in Montreal, at 10 o'clock in the morning.Present: Messrs.Omer-Ë.Milot, President, Joseph Hébert, Adrien Angers, J.-Albert Chartrand, Walter D.Lowe, commissioners, Alphonse Savoie, Secretary, C.-A.Gamache, Q.C., Legal Adviser.It is enacted as follows: 1.The present order is applied to any person who, directly or indirectly, sells or delivers milk within the limits of the region of Rivière-du-Loup.2.The region of Rivière-du-Loup includes the city of Rivière-du-Loup and the village of l'lsle Verte.3.Any milk dealer must pay to his producers-suppliers for each hundred pounds of milk which he receives from them, $1.45 P.O.B.business place of said dealer, and out of this sum pay the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec one half cent for each hundred pounds of milk received.4.Save the provisions of articles 5, 6, 7 and 8, no person shall, within the limits of said re-gion of Rivière-du-Loup offer, sell or deliver milk at prices inferior to 11 cents a pint and 19 cents a quart.5.No person shall, within the limits of said region of Rivière-du-Loup offer, sell or deliver milk to a grocery, a hotel, a restaurant, a dealer or to any other business establishment at prices inferior to 6 cents a half-pint, 10 cents a pint and 17^ cents a quart.6.No milk dealer shall sell, offer or deliver milk to distributors of dairy products at a price inferior to 60 cents a gallon.7.No milk dealer, cooperative society or cooperative syndicate shall offer, sell or deliver milk in bulk to hospitals or to charitable institutions at a price inferior to 60 cents a gallon.8° No person shall sell, offer or deliver milk in half-pint bottles, delivered to pupils, at a price inferior to 5 cents per half-pint.The present order cancels order No.7-54 published in the Quebec Official Gazette of January 16th, 1954, and shall come into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Signed: Omer-E.Milot, President, Adrien Angers, Commissioner, Joseph Hébert, Commissioner, J.-A.Chartrand, Commissioner, Walter D.Lowe, Commissioner.Certified: Alphonse Savoie, Secretary.39085-o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol 87, No.3 267 Commission de l'Industrie Laitière de la Province de Québec Ordonnance N° 37-55 Extrait des procès-verbaux des séances de la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec.Séance du jeudi, 13 janvier 1955, tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à Montréal, à 10 heures de l'avant-midi.Présents: MM.Omer-E.Milot, président, Joseph Hébert.Adrien Angers, J.-Albert Char-trand, Walter 1).Lowe, commissaires.Alphonse Savoie, secrétaire, C.-A.Gamache, CH., conseiller juridique.La Commission décrète ce qui suit: 1° La présente ordonnance s'applique à toute personne qui, directement ou indirectement, vend ou livre du lait dans les limites de la zone du Bas St-Laurent.2° La zone du Pas St-Laurent comprend la municipalité de la ville de Matane, la municipalité de la paroisse de St-Jérôme de* Matane.la municipalité de Ste-Félicité, le comté de Matapédia, la ville de Rimouski, la municipalité de Rimôuski-Est, les paroisses rie Saint-Robert, Sainte-Odile, Nazareth et Rie, la ville de Mont-Joli et la municipalité de Priceville.3°, Tout marchand de lait doit payer directement à ses fournisseurs-producteurs, pour chaque cent livres de lait qu'il reçoit de ceux-ci, $4.25 net, F.A.B.la place d'affaires dudit marchand, et, à même cette somme, payer à la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec, un demi-cent par cent livres de lait ainsi reçu.1° Sauf les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 nul ne peut, dans les limites de la zone du Bas St-Laurent, offrir, vendre ou livrer du lait à des prix inférieurs à 10 cents la chopine et 18 cents la pinte.5° Nul ne peut dans les limites de la zone du Bas St-Laurent, offrir, vendre ou livrer du lait à une épicerie, à un hôtel, où un restaurant, à des prix inférieurs à 6 cents le demiard, 9 cents la chopine et 17 cents la pinte.6° Nul marchand de lait ne peut vendre, offrir ou livrer du lait aux distributeurs de produits laitiers à un prix inférieur à 60 cents le gallon.7° Nul marchand de lait, société coopérative ou syndicat coopératif ne peut vendre, offrir ou livrer du lait en bidon, destiné aux hôpitaux et aux institutions de charité, à un prix inférieur à 60 cents le gallon.** 8° Nul ne peut vendre, offrir ou livrer du lait en bouteille d'un demiard pour distribution aux écoliers à un prix inférieur à 5 cents le demiard.\u2022 La présente ordonnance annule les ordonnances Nos 37-50, 37-50A, 37-50B, 73-50.73-50A, 73-50B, 46-50, 46-50A, 70-50, 70-50A.et entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Signé: Omer-E.Milot, président, Joseph Hébert, commissaire, Adrien Angers, commissaire, J.-A.Chartrand, commissaire, Walter D.Lowe, commissaire, Certifié: Alphonse Savoie, secrétaire.39085-o Dairy Industry Commission of the Province of Quebec Order No.37-55 Excerpts from the proceedings of the meetings of the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec.Meeting of Thursday, January 13th, 1955, held in the office of the Dairy Industry Commission in Montreal, at 10 o'clock in the morning.Present: Messrs.Omer-E.Milot, President, Joseph Hé'bert, Adrien Angers, J.-Albert Chartrand, Walter D.Lowe, commissioners, Alphonse Savoie, Secretary, C.-A.Gamache, Q.C., Legal Adviser.It is enacted as follows: 1.The present order is applied to any person who, directly or indirectly, sells or delivers milk within the limits of the zone of the Lower St.Lawrence.2.The zone of the Lower St.Lawrence includes the municipalities of the town of Matane, the municipality of the parish of St-Jérôme, the municipality of Ste-Kélicitc, the county of Matapédia.the town of Rimouski.the municipality of Rimouski-East, the parishes of Saint-Robert, Sainte-Odile, Nazareth and Bie.the town of Mont-Joli and the municipality of Priceville.3.Any milk dealer must pay to his producers-suppliers for each hundred pounds of milk which he receivers from them, $4.25 F.O.B.business place of said dealer, and out of this sum pay the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec, one half cent for each hundred pounds of milk received.4.Save the provisions of articles 5, 6.7 and S no person shall, within the limits of the zone of Lower St.Lawrence, offer, sell or deliver milk at prices inferior to 10 cents a pint and 18 cents a quart.5.No person shall within the limits of the zone of the Lower St.Lawrence, offer, sell or deliver milk to a grocery, a hotel or a restaurant, at prices inferior to 6 cents a half-pint, 9 cents a pint and 17 cents a quart.6.No milk dealer shall sell, offer or deliver milk to distributors of dairy products at a price inferior to 60 cents a gallon.7.No milk dealer, cooperative society or cooperative syndicate shall offer, sell or deliver milk in bulk to hospitals or to charitable institutions at a price inferior to 60 cents a gallon.8.No person shall sell, offer or deliver milk in half-pint bottles delivered to pupils at a price inferior to 5 cents per half-pint.The present order cancels orders Nos.37-50, 37-50A, 37-50B, 73-50.73-50A, 73-50B, 46-50, 46-50A, 70-50, 70-50A.and shall come into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Signed: Omer-E.Milot, President.Joseph Hébert, Commissioner, Adrien Angers, Commissioner, J.-A.Chartrand, Commissioner, Walter D.Lowe, Commissioner, Certified: Alphonse Savoie, Secretary.39085-o 268 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 Département de l'Instruction Publique N° 1220-54.Québec, le 5 janvier 1954.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Village d'Arthabaskaville, comté d'Arthabaska, en celui de \"Ville d'Arthabaska\", même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38976-2-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 1148-54.Québec, le 5 janvier 1955.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire d'Ély-Nord, dans le comté de Shefford, le lot N° 739 du cadastre officiel du canton d'Êly, pour l'annexer à la municipalité scolaire d'Ély-Ouest, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38977-2-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 981-54.Québec, le 5 janvier 1955.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Disraeli paroisse, dans le comté de Wolfe, les lots 38 à 43 inclusivement du rang III du canton de Garthby, comté de Wolfe, pour les annexer à la municipalité scolaire de St-Joseph-de-Coleraine, dans le comté de Mégantic.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38978-2-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 1303-54.Québec, le 8 janvier 1955.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de St-Roch-de-Bellecombe, dans le comté de Rouyn-Noranda, en celui de \"Dubois\", même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 39055-2-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 146-52.Québec, le 8 janvier 1955.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Jean-Port-Joli, dans le comté de lTslet, le lot 458 du cadastre officiel de St-Jean-Port-Joli, pour l'annexer à la municipalité scolaire de St-Aubert, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 39056-2-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 204-54.Québec, le 14 janvier 1955.Il a plu ati Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 5 janvier 1955, de détacher de la municipalité scolaire d'Ashford, dans le comté de l'Lslet, les lots 477, 481 et 482 du cadastre officiel de St-Roch-des-Aul-naies, pour les annexer à la municipalité scolaire de St-Aubert, même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet au 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique, 39073-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 1278-54.Québec, le 12 janvier 1955.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 5 janvier 1955, de changer le nom de la municipalité scolaire Department of Education No.1220-54.Quebec, January 5th, 1955.Application is made to change the name of the school Municipality of Arthabaskaville Village, county of Arthabaska, into that of \"Town of Arthabaska\", same countv.O.J.DÉSAULNIERS, 3S976-2-2 Superintendent of Education.No.1148-54.Quebec, January 5th, 1955.Application is made to detach from the school municipality of Êly-North, in the county of Shefford, lot No.739 of the official cadastre of the township of Ely, to annex it to the school municipality of Ély-West, in the same county.O.J.DÉSAULNIERS, 38977-2-2 Superintendent of Education.No.981-54.Quebec, January 5th, 1955.Application is made to detach from the school municipality of Disraeli parish, in the county of Wolfe, lots 38 to 43 inclusive, range III of the township of Garthby, county of Wolfe, in order that they be annexed to the school municipality of St.Joseph-de-Coleraine, in the county of Megantic.O.J.DÉSAULNIERS.38978-2-2 Superintendeut of Education.No.1303-54.Quebec, January 8th, 1955.Application is made to change the name of the School Municipality of St.Roch-de-Bellecombe, in the county of Rouyn-Noranda, to that of \"Dubois\", same coimty.^ O.J.DÉSAULNIERS, 39055-2-2 Superintendent of Education.No.146-52.Quebec, January 8th, 1955.Application is made to detach from the school municipality of St-Jean-Port-Joli, in the county of I'Islet, lot 458 of the official cadastre of St-Jean-Port-Joli, to annex it to the school municipality of St-Aubert, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 39056-2-2 Superintendent of Education.No.204-54.Quebec, January 14, 1955.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated January 5, 1955, has been pleased to detach from the school municipality of Ashford, County of l'lslet, lots 477, 481 and 482 of the official cadastre of St-Roch-des-Aulnaies, to annex them to the school municipality of St-Aubert, same County.This Order in Council will take effect on July 1st, 1955.OvJ.DÉSAULNIERS, 39073 Superintendent of Education.No.1278-54.Quebec, January 12st, 1955.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated January 5st, 1955, has been pleased to change the name of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 269 d'Ashford, dans le comté de ITslet, en celui de \"St-Damase-de-lTslct,\" même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet huit jours après la publication de cet avis dans la Gazette Officielle de Québec.Le Surintendant de l'Instruction publique, 39073-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 894-54.Québec, le 12 janvier 1955.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 5 janvier 1955, de détacher de la municipalité scolaire de St-Didace village, comté de Maskinongé, le lot N° 905 du cadastre officiel de St-Didacc, pour l'annexer à la municipilité scolaire de la paroisse de St-Gabriel-dc-Brandon, comté de Berthier.Cet arrêté ministériel prendra effet au 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique, 39073-o O.J.DÉSAULNIERS.Département des Terres et Forêts school municipality of Ashford, County of ITslet, into that of \"St-Damase-de-lTslct\", same County.This Order in Council will take effect eight days after publication of this notice in the Quebec Official Gazette.O.J.DÉSAULNIERS, 39073 Superintendent of Education.No.894-54.Quebec, January 12st, 1955.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated January 5st, 1955 has been pleased to detach from the school municipality of the village of St-Didace, County of Maskinongé, lot No.905 of the official cadastre of St-Didace, to annex it to the school municipality of the parish of St-Gabriel-de-Brandon, County of Berthier.This Order in Council will take effect of July 1st, 1955.O.J.DÉSAULNIERS, 39073 Superintendent of Education.Department of Lands and Forests AVIS Cadastre officiel du canton de Mazenod division d'enregistrement de Témiscamingue.Avis est par la présente donné que dans le rang VIII les lots 30-52 et 30-53 sont ajouté et le lot 30-34 est corrigé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 30 décembre 1954.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 39074-o A VILA BÉDARD.NOTICE Officiai cadastre of the township of Mazenod registration division of Témiscamingue., Notice is hereby given that in range VIII lots 30-52 and 30-53 are added and lot 30-54 is corrected in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, December the 30th, 1954.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 39074-o Deputy Minister.Pépartement du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative au commerce de détail dans la cité de Chicoutimi et un rayon de cinq (5) milles de ses limites à l'exclusion de la cité d'Arvida, rendue obligatoire par le décret numéro 996 du 2 octobre 1952, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil les modifications suivantes audit décret: 10 Les deux parties contractantes de deuxième part seront remplacées par la suivante: \"Le Syndicat des Employés de Magasins de Chicoutimi\" 2°.Le paragraphe \"a\" de l'article I sera remplacé par le suivant: \"a) Le terme \"magasin de détail\" désigne tout établissement où se fait en tout ou en partie, au détail, l'un des commerces suivants, soit que telles opérations ou transactions constituent le commerce principal de tel établissement ou qu'elles soient secondaires à tout autre qpmmerce au gros ou au détail, à savoir: nouveautés, marchan- Department of Labour .NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the retail trade in the city of Chicoutimi and a radius of five (5) miles from its limits, with the exception of the city of Arvida, rendered obligatory by the decree No.996 of October 2, 1952, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor iu Council the following amendments to the said decree: 1.The two contracting parties of the second part will be replaced by the following: \"Le Syndicat des Employés de Magasins de Chicoutimi\".1.Subsection \"a\" of section I will be replaced by the following: \"a) The term \"retail store\" means any establishment in which one of the following trades is carried on, in whole or in part, on a retail basis, whether such operations or transactions constitute the main trade of such establishment or be accessory to any other wholesale or retail trade, namely: Novelties, dry goods, grocery, meats, 270 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 dises-sèehes, épicerie) boucherie, épicerie-boucherie, épicerie-licenciée, restaurant-épicerie, quincaillerie, ferronnerie, pharmacie, chaussures, chapeaux, fourrures, tabac, cigares, cigarettes, fleurs, objets de fantaisie, bibelots, chocolats et bonbons, biscuits et gâteaux, matériaux de construction, peinture, papier-tenture, articles de plomberie, meubles, articles de sports, radios, laveuses, poêles et accessoires, farine et moulée, instruments de musique, machines à coudre.On désigne aussi les bazars de $0.05 à SI.00 ou plus, les magasins généraux, les librairies et les papeteries.\" 3° Le paragraphe \"//' de l'article IV sera remplacé par le suivant : \"b) La semaine régulière du travail est la suivante: 1.Dans les épiceries, boucheries, épicerics-boucherics, épiceries-licenciées, restaurants-épiceries: Quarante-sept et demie (47J^)heures poulies salariés du sexe féminin et cinquante et demie (50]¦¦¦>) heures pour les salariés du sexe masculin, réparties comme suit : Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, la veille de Noël et la veille du premier de- l'An: de S.00 a.m.à f>.3() p.m.pour les salariés du sexe masculin et de S.30 a.m.à 5.30 p.m.pour les salariés du sexe féminin.Les vendredi et veilles de l'êtes chômées et les trois (3) jours ouvrables précédant la veille de Noël, c'est-à-dire trois (3) jours où le travail devrait cesser à 5.30 p.m., de S.00 a.m.à 9.00 p.m.pour les salariés du sexe masculin et de S.30 a.m.à 9.00 p.m.pour les salariés du sexe féminin.2.Dans les autres magasins de détail régis par le décret: Quatrante-quatre et demie (44]) heures pour les salariés «lu sexe féminin et quarante-sept et demie (47] 2) heures pour les salariés du sexe masculin, reparties comme suit: Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, la veille de Noël et la veille du Premier «le l'An: de S.30 a.m.à 5.30 p.m.pour les salariés «lu sexe masculin et de 9.00 a.m.à 5.30 p.m.pour les salariés «lu sexe féminin.Les vendredi et veilles de fêtes chômées et les trois (3) jours ouvrables précédant la veille de Noël, c'est-à-dire trois (3) jours où le travail devrait cesser à 5.30 p.m., «le 8.30 a.m.à 9.00 p.m.pour les salariés «lu sexe masculin et «le 9.00 a.m.à 9.00 p.m.pour les salariés du sexe féminin.\" \u20221° Le paragraphe \"6\" de l'article V sera remplacé par le suivant : \"b) Le salaire des salariés soumis à la semaine de quarante-quatre et demie (44]) heures ou «le quarante-sept et demie (47]^) heures ne doit en rien être affecté par les fêtes chômées.\" 5° Le paragraphe \"a\" de l'article VII sera remplacé par le suivant: \"VIL Salaires- minima: a) Les taux de salaires minima sont les suivants: Taux Hebdomadaires Hommes- Femmes Chef de département ou premier commis.§49.00 $34.00 Chef d'allée.38.00 30.00 Comptable.47.00 Étalagiste.47.00 Boucher.49.00 Note: Tous les commis-bouchers sont soumis à la même échelle de salaires que les commis.Commis: 1er semestre.18.00 17.00 2ème semestre.20.00 18.00 2ème année.23.00 20.00 3ème année.27.00 23.00 4ème année.30.00 25.00 5èmc année.35.00 grocery-butcher shop, licensed grocery, restaurant-grocery, hardware, drugs, shoes, hats, furs, tobacco, cigars, cigarettes, flowers, fancy articles, bibelots, chocolate and bonbons, biscuits and cakes, building materials, paint, wall-paper, plumbing, furniture, sporting goods, radios, washing machine.1', stores, ranges and accessories, flour and fee«l.stuffs, musical instruments, sewing machines.The term also applies to $0.05 to $1.00 stores, general stores, bookstores and stationeries.\" 3.Subsection \"6\" of section IV will be replaced by the following: \"!>) The standard work week shall be as follows: 1.In groceries, butcher shops, groceries-butcher shops, licensed groceries, restaurants-groceries: Forty-seven and a half (47) '\u2022>) hours for female employees and fifty nnd a half (5OJ/0 hours for male employees, distributed as follows: On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday and Christmas and New Years' eves: 8.00 a.m.to 5.30 p.m.for male employees, and 8.30 a.m.to 5.30 p.m.for female employees.On Friday and holiday eves, and on the three (3) working days preceding Christmas, i.e.three (3) days on which work should cease at 5.30 p.m., 8.00 a.m.to 9.00 for male employees, and 8.30 a.m.to 9.00 p.m.for female employees.2.In other retail stores governed by the decree: Forty-four and a half (44)4) hours for female employees, and forty-seven and a half (47^) hours for male employees, distributed as follows: On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Christmas and New Year's eves: S.30 a.m.to 5.30 p.m.for male employees, and 9.00 a.m.to 5.30 p.m.for female employees.On Friday ami holiday eves, and on the three (3) working days preceding Christmas, i.e.three (3) days on which work should cease at 5.30 p.m., 8.30 a.m.to 9.00 p.m.for male employees, and 9.00 a.m.to 9.00 p.m.for female employees.\" 4.Subsection \"//' of section V will be replaced by the following: \"/;) The wages of employees subject to the forty-four ami half (44>£), fifty and a half (50^) and forty-seven and a half (47 J^) hour week shall not be affected by holidays.\" 5.Subsection \"a\" of section VII will be replaced by the following: \"VII.Minimum wages: a) The minimum rates of wages shall be as follows: Weekly rates , Males Female Departmental manager or chief clerk.849.00 834.00 Floorwalker.38.00 30.00 Accountant.47.00 Window dresser.47.00 Butcher.49.00 Note: All butcher clerks shall be paid the clerks' rates.Clerks: 1st six months.18.00 17.00 2nd six months.20.00 18.00 2nd vear.23.00 20.00 3rd year.27.00 23.00 4th year.30.00 25.00 5th vear.35.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.8 271 Tous les salariés du sexe féminin de cette catégorie ayant quatre (4) années d'expérience ou plus doivent être payés comme suit: 1/3 classe A.32.00 1/3 classe 1$.29.00 1/3 classe C.27.00 Tous les salariés du sexe masculin de cette catégorie ayant cinq (ô) années d'expérience ou plus doivent être payés comme suit : 1/3 classe A.42.00 1/3 classe B.39.00 1/3 classe C.37.00 Teneurs de livres: même taux que les commis jusqu'à concurrence de cinq (5) années accomplies.Subséquemment.42.00 32.00 Caissier ou caissière: même taux que les commis.Salariés à commission: même échelle de base que l'échelle minimum des commis.Livreur, habituellement chargé de la livraison avec camion, automobile ou voiture à traction animale.43.00 Aide-livreur, chargé habituellement de la livraison avec camion, automobile ou voiture à traction animale.35.00 Aide-livreur mineur: $2.00 de moins par semaine que l'aide-livreur.lit marque: Aide-livreur comprend tout employé qui s'occupe de la livraison à bicyclette ou autrement mais qui n'a pas la responsabilité de la livraison par camion, automobile ou voiture à traction animale.Livreur à bicyclette.15.00 La bicyclette et ses accessoires doivent être fournis par l'employeur qui doit également pourvoir aux réparations.Livreur à bicyclette de plus de seize (10) ans: même taux que les commis.Couturière: même taux que les commis.\" 6° L'alinéa suivant sera ajouté au paragraphe V] de l'article VII: \"Toutefois, pour bénéficier de ces taux, tout salarié surnuméraire devra avoir travaillé l'équivalent de 26 semaines de trente (30 )heures pour les femmes et de 26 semaines de quarante (10) heures pour les hommes.Pendant ces 26 semaines, le taux horaire sera de 80.40.\" 7° Le paragraphe \"/\" de l'article VI sera biffé.8° Le paragraphe \"c\" de l'article VIII sera biffé.9° L'article IX sera biffe.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 22 janvier 1955.39063-o All female employees of this category with four (4) or more years of experience shall be paid as follows: 1/3 class A.32.00 1/3 class B.28.00 1/3 class C.27.00 All male employees of this category with five (5) or more years of experience shall be paid as follows: 1/3 class A.42.00 1/3 class B.39.00 1/3 class C.37.00 Book-keepers: Clerks' rates up to the/fifth (5th) vear, inclusive.Thereafter.42.00 32.00 Cashier: clerks' rates.Commissi mi salesmen: same basic minimum scale as clerks.Delivery employee habitually in charge of the delivery with truck, automobile or horse-drawn vehicle.43.00 Delivery employee's helper, doing the delivery with truck, automobile or horsed rawn vehicle 35.00 (.'ndcr-age delivery employee's helper: 82.00 less per week than delivery employee's helper.Note: Delivery employees' helpers include all employees doing the delivery with bicycle or otherwise and who are not responsible for the delivery make with trucks, automobiles or horse-drawn vehicles.Delivery employee (with bicycle) 15.00 The bicycle and its accessories shall be supplied by the employer who, also, shall keep same in repair.Delivery employees (with bicycle) over 16 years of age: Clerk's rates.Seemstress: Clerks' rates.\" 6.The following paragraph will be added to subsection \"c\" of section VII: \"However, to be entitled to these rates, occasional employees must work the equivalent of 26 weeks of thirty (30) hours in the case of female employees, and 20 weeks of forty (40) hours in the case of male employees.During these 26 weeks, the hourly rates shall be 80.40.\" 7.Subsection \"/\" of section VI will be deleted.8.Subsection \"e\" of section VIII will be deleted.9.Section IX will be deleted.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, January 22nd, 1955.39063-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie du verre dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 878 du 2 août 1950, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil les modifications suivantes audit décret: NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the * collective agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the glass processing industry in the region of Quebec, rendered obligatory by decree No.878 of August 2nd, 1950, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the said decree: 272 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 1° Le paragraphe \"a\" de l'article III sera remplacé par le suivant: \"III.Classification et salaires: a) Les taux de salaires sont les suivants pour les salariés des classifications ci-après mentionnées: Suction I 1.Subsection \"a\" of section III will be replaced by the following: \"III.Classification and wages: a) The following shall be the rates of wages for the employees in the classifications hereunder mentioned : Part 1 L'heure Compagnon Compagnon senior junior Monteur.81.28 $1.14 Biseautcur.1.25 1.11 Argentcur.1.20 1.06 Tailleur-mastiqueur.1.20 1.06 Per hour Senior Junior Journeyman Journeyman Setter.$1.28 $1.14 Bevcller.1.25 1.11 Silverer.1.20 1.06 Cutter-putty layer .1.20 1.06 Section 2 Part 2 Per hour Polisseur de rayures, polisseur (disque Scratch polisher, spinner, examiner, buf- horizontal), vérificateur, polisseur de fer, belt worker, froster, sand polisher, biseaux, polisseur (courroie), gi- L'heure draughtsman.$1.01 vreur, sableur, dessinateur.$1.01 Spray painter, spray painter's helper, Aspergeur, aide-aspcrgeur.0.94 silvcrer's helper.0.94 Expéditeur (plein temps).1.11 Shipper (full time).1.11 Empaqueteur.0.99 Packer.0.99 Conducteur de camion.1.04 Truck driver.1.04 Aide d'entrepôt, aide monteur.0.96 Warehouseman's helper, setter's helper.0.96 Préposé à l'entretien.1.12\" Maintenance man.1.12\" 2° Les paragraphes \"c\" et \"d\" de l'article III 2.Subsections \"c\" and \"d\" of section III will seront remplacés par les suivants: be replaced by the following: \"c) Dans la section I du paragraphe \"a\" du \"c) In part 1 of subsection \"a\" of thej>resent présent article, sont classés \"Compagnon Sé- section, the rates under \"Senior Journeyman\" nior\" les salariés qui ont terminé leur apprentis- shall apply to those employees having completed sage dans un des métiers de cette catégorie et their apprenticeship in one of the trades of this ont travaillé 18 mois comme compagnon junior, category and have worked 18 monts as junior Sont classés \"Compagnon Junior\" les salariés journeymen.The rates under \"Junior Journey- qui ont terminé leur apprentissage dans un des man\" shall apply to those having completed métiers de l'industrie du verre mentionné à their apprenticeship in one of the trades of the ladite section.\" glass industry mentioned in part 1.\"d) Dans la section 2 du paragraphe \"o\" du \"d) In part 2 of subsection \"a\" of the present présent article, sont classés les salariés qui ont section are grouped the employees having com- terminé leur aprentissage dans une des caté- pleted their apprenticeship in one of the catego- gories d'emploi de cette section.\" ries of employment mentioned in part 2.\" 3° La paragraphe \"/\" de l'article III sera 3.Subsection \"/\" of section III will be replaced remplacé par le suivant; by the following: \"/) Préposé à l'entretien: Le terme \"homme \"/) Maintenance man: The term \"mainte-d'entretien\" désigne tout salarié qui, à l'exception nance man\" means any employee, excepting des gardiens de nuit, durant les heures régulières night watchmen, who, during regular working de travail, s'occupe de tous les travaux d'entre- hours, does any work connected with mainte-tien de l'outillage, de la machinerie, des bâtisses, nance, tools, machinery, buildings, properties, des propriétés, du chauffage ou exécute tous heating or does any other work not determined autres travaux non déterminés au présent décret, herein.4° Le paragraphe \"/\" de l'article VI sera 4.Subsection \"/\" of section VI will be replaced remplacé par le suivant: by the following: \"/) L'employé qui n'a pas bénéficié des vacan- \"/) Employees who did not benefit by a ces de la manière ci-haut décrite, a le droit de vacation as determined above may, when the réclamer, lorsque le délai pour les vacances est vacation period has expired, claim the equivalent expiré, l'équivalent en argent pour la période de in money for the vacation period to which they vacances auxquelles il a droit ou de demander are entitled or a vacation of one week with pay, une semaine de vacances payées à la date qui lui at a date chosen by them.Should an employee conviendra.Si l'employé est congédié ou laisse be dismissed or should he quit before he has taken son emploi avant d'avoir bénéficié des vacances the vacation to which he is entitled, the employer auxquelles il a droit, l'employeur doit lui payer shall pay him, when the employment comes to lors de la cessation de l'emploi, l'équivalent en an end, the remuneration for the vacation period argent pour la période des vacances auxquelles to which the employee is entitled.\" l'employé a droit.\" 5° L'article VII sera remplacé par le suivant: 5.Section VII will be replaced by the following: \"VII.Jours chômés et payés: Le jour de Noël, \"VIL Holidays with pay: Christinas Day, le Premier de l'An, la Saint-Jean-Baptiste, la New Year's Day, St.Jean Baptiste Day, Labour fête du Travail sont des jours chômés et payés.Day shall be holidays with pay.The employee's La rémunération du salarié pour ces jours de fêtes pay for these days shall be computed at the doit être calculée à raison de salaire simple pour regular rate for the standard daily hours of the le nombre d'heures d'une journée régulière de establishment, providing he has worked the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 273 travail de l'établissement, pourvu qu'il ait travaillé le jour ouvrable qui précède et celui qui suit le jour de fête, à moins d'une permission accordée par l'employeur.\" 6° Le paragraphe \"b\" de l'article VIII sera remplacé par le suivant: \"b) Travaux locaux exécutés en deçà du réseau des autobus de la ville (un passage): L'employeur doit payer les frais de transport de l'atelier au chantier, et vice versa, ainsi que le temps régulier où supplémentaire des salariés selon le cas, jusqu'à ce que le travail soit terminé ou suspendu et que les hommes soient retournés à l'atelier.\" 7° Le paragraphe \"b\" de l'article X sera remplacé par le suivant: \"b) L'apprenti ne doit pas être âgé de moins de 16 ans (exception faite des cas spéciaux qui peuvent survenir, lesquels doivent être approuvés, par écrit, par le Comité Paritaire).Il doit pouvoir parler, lire et écrire l'anglais ou le français et connaître suffisamment l'arithmétique pour faire les calculs nécessaires à l'exécution du travail auquel il se destine.\" 8° Le paragraphe \"c\" de l'article X sera remplacé par le suivant: \"c) L'apprenti doit être employé là où se trouvent les facilités voulues pour apprendre son métier.Le période d'apprentissage est de trois (3) années de 250 jours.au minimum, chacune.Si l'établissement de son employeur fonctionne normalement pendant moins de 250 jours ouvrables dans une année d'apprentissage, et si, pour cette raison, les 250 jours d'apprentissage d'une année ne sont pas faits, le nombre de jours qui manque doit être ajouté à sa période d'apprentissage de trois (3) ans et son taux de salaire pour ce terme additionnel est celui payable pour le dernier terme d'apprentissage.Cependant, si le manque de jours d'apprentissage dans une année n'est pas imputable à l'employeur, ou si l'apprenti en est responsable, l'année courante d'apprentissage est alors prolongée à raison du nombre de jours manquant, et la période de trois ans prolongée en conséquence.\" 9° Le paragraphe \"d\" de l'article X sera remplacé par le suivant: \"d) Les taux de salaires des apprentis sont les suivants: l'heure Premier semestre.SO.56 Deuxième semestre.0.60 Troisième semestre.0.65\" 10° Le paragraphe \"e\" de l'article X sera radié.11° L'article XI sera remplacé par le suivant: \"XI.Durée du décret: Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec et demeure en vigueur pour une année.Il se renouvelle automatiquement d'année en année à moins que dans un délai de pas plus de soixante (60) ni de moins de trente (30) jours avant la date de son expiration, l'une des parties, contractantes ne donne un avis écrit, à ce contraire, à l'autre partie et au Ministre du Travail.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 22 janvier 1955.39063-o working day before and the one following the holiday, unless otherwise authorized by the employer.\" 6.Subsection \"b\" of section VIII will be replaced by the following: \"b) Local jobs within one city bus fare: The employer shall pay transportation to and from shop to job and pay employees at regular or overtime rates, as the case may be, until such time as the job is completed or suspended and the men returned to shop.\" 7.Subsection \"b\" of section X will be replaced by the following: \"b) An apprentice shall not be under 16 years of age (except in special cases that may arise, subject to the approval, in writing, of the Parity Committee).He shall be able to speak, read and write either the English or French language and have sufficient knowledge of arithmetic to make the calculations required in the work or craft in which he is apprenticed.\" 8.Subsection \"c\" of section X will be replaced by the following: \"c) The apprentice shall be employed where adequate facilities are provided for his learning the trade or craft in which he is apprenticed.The period of apprenticeship shall consist of three (3) years of at least 250 days per year.If the employer's shop is operating normally for less than 250 working days in any apprenticeship year, and the apprentice serves less than 250 days in any apprenticeship year on this account, the number of days lacking shall be added to his apprenticeship period of three (3) years and his rate of wages for such additional term of apprenticeship shall be the rate payable for the last term of his apprenticeship.If, however, the lack of working days of the 'apprentice in one apprenticeship year is due to causes beyond the control of the employer, or to the fault of the apprentice, then the current year of apprenticeship is considered as lengthened to the extent of such loss of working days and the three year period of apprenticeship lengthened accordingly.\" 9.Subsection \"d\" of section X will be replaced by the following: \"d) Rates of wages for apprentices shall be: Per hour First six months.SO.56 Second six months.0.60 Third six months.0.65\" 10.Subsection \"e\" of section X will be deleted: 11.Section XI will be replaced by the following: \"XL Duration of the decree: The present decree comes into force from the date of its publication in the Quebec Official Gazette and remains in force for a period of one year.It renews itself automatically from year to year, unless one of the contracting parties notified the other party and the Minister of Labour, in writing, to the contrary1 within the period extending from the 60th to the 30th day before the date of its expiration.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parlies mav wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, January 22nd, 1955.39063-o 274 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, Scantier 1955, Tome 87, N° 3 Ministère des Finances Assurances Loi des Assurances de Québec AVIS Les soussignés, Laurent Labclle, industriel, domicilié au N° 27S5 Chemin Ste-Catherine, Montréal; Paul-Emile Ménard, gérant, domicilié au N° 359 boulevard St-Joseph est, Montréal; Henri Gareau, comptable, domicilié au N° 2925, boulevard Graham, ville Mont-Royal; J.-Édouard Jcannotte, notaire, domicilié au N° 3575 rue Sherbrooke est, Montréal; Jean Trudel, avocat, conseil en loi de la Reine, domicilié au N° 3503, rue Addington, Montréal, donne avis qu'ils ont l'intention de s'adresser au Lieutenant-gouverneur en conseil, le priant de les constituer en corporation de compagnie d'assurance, aux fins de transiger les groupes suivants d'assurance et de réassurance: contre les accidents, d'automobiles, d'aviation, contre le vol avec ou sans effraction, de crédit, contre les explosions, contre le feu, contre le faux, de garantie, contre la grêle, industrielle, responsabilité publique, de navigation intérieure, des transports intérieurs, sur le bétail, maritime océanique, contre le bris de glace, contre la maladie, contre les défectuosités dans les arrosoirs automatiques, sur les chaudières à vapeur, contre les cyclones, contre l'intempérie, ou tout autre groupe d'assurance ou de réassurance, excepté l'assurancc-vie, avec siège social en la cité de Montréal, au capital-actions de S500,-000.00 divisé en 5,000 actions de S100 chacune, le tout en conformité de la loi des assurances de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 299).^ Le nom de la compagnie sera: \"La Compagnie d'Assurance du Club des Automobilistes de Montréal\".Montréal, 20 décembre 1954.LAURENT LABELLE, PAUL EMILE MÉNARD, HENRI GAREAU, J.-ÉDOUARD JEANNOTTE.38919-53-4-û JEAN TRUDEL.Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que \"The Veritas Insurance Company of Sweden\", enregistrée sous le numéro 554, a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 1887 qui l'autorise, à compter du 15 décembre 1954, à effectuer dans la Province des contrats d'assurance relatifs aux genres suivants: Incendie et accessoirement \u2014 agitation civile, choc de véhicules, chute d'aéronef, défectuosité d'extincteurs automatiques, explosion limitée ou inhérente, fuite d'eau, grêle, intempéries, ouragan, tremblement de terre.Le siège social de la compagnie est situé à Stockholm, Suède.La compagnie a nommé monsieur Paul-E.Tremblay, 465, rue St-Jean, Montréal, son procureur dans la Province.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 8 janvier 1955.Pour le Ministre des finances de la Province, GEORGES LAFRANCE, 39019-2-2-o Surintendant des assurances.- Department of Finance Insurances Quebec Insurance Act NOTICE The undersigned, Laurent Labelle, industrialist, residing at No.2875 St.Catherine Road, Montreal; Paul Emile Ménard, manager, residing at No.359 St.Joseph Boulevard, east, Montreal; Henri Gareau, accountant, residing at No.2925 Graham Boulevard, town of Mount Royal; J.Edouard Jcannotte, notary, residing at No.3575, Sherbrooke Street, cast, Montreal; Jean Trudel, advocate, Queen's Counsel, residing at No.3503, Addington Street, Montreal, give notice that they intend applying to the Lieutenant-Governor in Council, praying him to incorporate them as an insurance company, for the purpose of transacting one of the following groups of insurance and reinsurance: accident, automobile, aviation, larceny, housebreaking or burglary, credit, explosion, fire, forgery, quarantce, hail, industrial, public liability, inland marine, inland transpoi tatioji, livestock, ocean marine, plate glass, sickness, spinkler leakage, steam boiler, tornado, weather, or any other class of insurance or reinsurance, save ami except life insurance, with head office in the city of Montreal, with a share capital in the amount of $500,000.00 divided into 5,000 shares of $100 each, all of which pursuant to the Quebec Insurance Act (R.S.Q.1941, chapter 299).The name of the company shall be: \"La Compagnie d'Assurance du Club des Automobilistes de Montréal\".Montreal, December 20th, 1954.LAURENT LABELLE, PAUL EMILE MÉNARD, HENRI GAREAU, J.EDOUARD JEANNOTTE, 38919-53-4 JEAN TRUDEL.Notice of Ussue of License and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"The Veritas Insurance Company of Sweden\", registered under number 554, has obtained the license and certificate of registry number 1887 authorizing it, as from the 15th of December 1954, to undertake in the Province contracts of insurance of the following classes: Fire and supplementary thereto \u2014 civil commotion, earthquake, falling aircraft, hail, impact by vehicles, limited or inherent explosion, sprinkler leakage, water damage, weather, windstorm.The head office of the company is situate in Stockhokm, Sweden.The company has appointed Mr.Paul E.Tremblay, 465 St.John Street, Montreal, its attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 8th of January 1955.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 39019-2-2-o Superintendent of Insurance. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.86, No.3 275 Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que \"Bâloise Fire Insurance Company of Canada\" et en français, \"La Bâloise, Compagnie d'assurance contre l'incendie au Canada\", enregistrée sous le numéro 553, a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 1880 qui l'autorise, à compter du 8 décembre 1954, à effectuer dans la Province des contrats d'assurance relatifs aux genres suivants: Incendie et accessoirement \u2014 agitation civile, choc de véhicules, chute d'aéronef, défectuosité d'extincteurs automatiques, explosion limitée ou inhérente, fuite «l'eau, intempéries, ouragan, tremblement de terre; Automobile.Le siège social «le la compagnie est situé à 80 ouest, rue King, Toronto, Ontario.La compagnie a nommé monsieur Michael Corse-Scott, 585, rue McGill, Montréal, son procureur dans la Province.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 8 janvier 1955.Pour le Ministre des finances de la Province, GEORGES LAFRANCE, 39019-2-2-o Surintendant des assurances.Nominations Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur, «le l'avis et du consentement du Conseil Exécutif, «le nommer par lettres patentes sous le grand sceau de la province, au nom de Sa Majesté, la personne dont le nom suit: Québec, le 15 décembre 1954.M.James P.Anglin, avocat, membre du Barreau de la province de Québec, et pratiquant comme tel dans la cité de Montréal: conseil en loi de la Reine.Il a plu à San Honneur le Lieutenant-gouverneur, «le l'avis et du consentement du Conseil Exécutif, et par commissions, de faire les nominations suivantes: Québec, le 15 décembre 1954.M.Alfred M.West, C.R., de Montréal, et membre du Barreau de la province: juge municipal de la ville de Montréal-Ouest, avec les juridictions, attributions, droits, prérogatives, devoir et pouvoirs attachés à cette fonction et pour agir comme recorder en ce qui concerne les juridictions attribués à un recorder par les lois du Parlement du Canada, selon l'article 4 de la loi 1-2 Elizabeth II, chapitre 52.Québec, le 17 décembre 1954.M.Henri Masson-Loranger, avocat, membre du Barreau de la province de Québec, conseil en loi de la Reine et substitut du Procureur général, à Montréal: juge des sessions, avec résidence dans la cité de Montréal ou le voisinage immédiat, à compter du 16 janvier 1955.39062-o Proclamation Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.IL.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses Notice of Issue of License and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"Baloise Fire Insurance Company of Canada\", and in French, \"La Bâloise, Compagnie d'assurance contre l'incendie au Canada\", registered under number 553, has obtained the license and certificate of registry number 1886 authorizing it, as from the 8th of December 1954, to undertake in the Province contracts of insurance of the following classes: Fire and supplementary thrreto \u2014 civil commotion, earthquake, falling aircraft, impact by vehicles, limited or inherent explosion, sprinkler leakage, water damage, weather, windstorm; Automobile.The head office of the company is situate at 80 King Street West, Toronto, Ontario.The company has appointed Mr.Michael Corse-Scott, 485 McGill Street, Montreal, its attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 8th of January 1955.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 39019-2-2-o Superintendent of Insurances.Appointments His Honour the Lieutenant-Governor, with the advice and consent of the Executive Council, has been pleased to appoint by letters patent under the great Seal of the Province in the name of Her Majesty, the person whose name follows: Quebec, December 15th.1954.Mr.James P.Anglin, advocate, member of the Bar of the Province of Quebec, and practising, in that capacity, in the city of Montreal: Queen's Counsel.His Honour the Lieutenant-Governor, with the advice and consent of the Executive Council, and by Commission, has been pleased to make the following appointments: Quebec, December 15th, 1954.Mr.Alfred M.West.Q.C., of Montreal, and member of the Bar of the Province: Municipal Judge of the town of Montreal West, with the jurisdictions, attributions, rights, prerogatives, duties and powers attaching to said office, and to act as Recorder in that which concerns the jurisdictions attributed to a recorder by the Acts of Parlement of Canada, according to section 4 of Act 1-2 Elizabeth II, chapter 52.Quebec, December 17th, 1954.Mr Henri Masson-Loranger, advocate, member of the Bar of the Province of Quebec, Queen's Counsel and Crown Prosecutor, at Montreal: Judge of the Sessions of the Peace, with residence in the city of Montreal or in its immediate vicinity, as from January 16th, 1955.39062 Proclamation Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.SJ ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada, and Her 276 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° 3 autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur / A TTENDU que le se-général, ) **¦ crétairc (les com- C.E.Cantin.\\ missaires dûment nom-( mes pour les fins de la section II de la Loi des paroisses et des fabriques (Statuts refondus, 1941, chapitre 308), pour le diocèse catholique romain d'Amos, a, sous l'autorité des dispositions de l'article 18 de ladite loi, transmis au Lieutenant-gouverneur en conseil le décret de l'autorité ecclésiastique dudit diocèse, en date du 3 juin 1954, érigeant en paroisse canonique le territoire ci-après décrit, sous le nom de la paroisse du Christ-Roi; Attendu que le secrétaire desdits commissaires a, de plus, transmis un certificat attestant qu'après la publication de ce décret et des avis requis par les dispositions de l'article 17 de la Loi des paroisses et des fabriques, il n'a été déposé à son bureau, dans le délai prescrit, aucune opposition à la reconnaissance de ce décret canonique pour les fins civiles; Attendu que les formalités prescrites par cette loi ont été remplies et qu'il y a lieu d'émettre une proclamation pour l'érection civile de cette paroisse.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 34, en date du 5 janvier 1955, et conformément aux dispositions de la Loi des paroisses et des fabriques, Nous avons confirmé, établi et reconnu, et, par les présentes, confirmons, établissons et reconnaissons les limites et bornes assignées par ledit décret canonique à la paroisse du Christ-Roi, dans le diocèse catholique romain d'Amos, comme suit, à savoir: Un territoire situé partie dans le canton de Dalquier et partie dans le canton de Figucry, comprenant tous les lots ou parties de lot et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, rues, nielles, emprise de chemin de fer, cours d'eau ou partie d'iceux, renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection de la rive gauche ou rive ouest de la rivière Harricana avec la ligne separative des rangs VI et VII du canton de Figucry; de là, passant par les lignes et démarcations suivantes, en continuité les unes des autres: dans le canton de Figuery, en référence au cadastre officiel pour ledit canton, Ladite ligne separative des rangs VI et VII en allant vers l'ouest, la ligne separative des lots 6 et 7, rang VII; la ligne separative (les rangs VII et VIII en allant vers l'ouest; la ligne latérale ouest du lot 1, rang VIII; la ligne separative des rangs VIII et IX en allant vers l'est; la ligne separative des lots 9 et 10 de chacun des rangs IX et X; la ligne separative des cantons de Figuery et de Dalquier en allant vers l'est; puis, dans le canton de Dalquier, en référence au cadastre officiel pour ledit canton, la ligne separative des lots 15 et 16 de chacun des rangs I, II, III et IV; la ligne separative des rangs IV et V en allant vers l'est jusqu'à la rive gauche ou rive ouest de la rivière Harricana et enfin, cette dite rive en descendant le cours de la rivière dans des directions sensiblement ouest et sud jusqu'au point de départ; lequel territoire sera détaché de la paroisse de Sainte-Thérèse-d'Amos et sera érigé en une paroisse distincte, pour les fins civiles, sous le nom de paroisse du Christ-Roi, diocèse d'Amos.other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender, of the Faith.To all to whom these present letters shall come or whom the same may concern.Greeting: PROCLAMATION C.E.Cantin.(V\\7\"HEREAS the secretary Deputy Attorney ) * * for the commissioners General.j duly appointed for the purpo-\\ ses in division II of the parish and Fabrique Act (Revised Statutes, 1941 chapter 308), for the Roman Catholic Diocese of Amos, has, under the authority of the provisions of section 18 of the said Act, submitted to the Lieutenant-Governor in Council, a decree of the ecclesiastical authorities of said diocese, dated June 3rd, 1954, erecting the territory hereinafter described, into a canonical parish, under the name of parish of Christ-Roi; Whereas the secretary for said commissioners has, moreover, transmitted a certificate to the effect that after publication of said decree and the notices required by the provisions of section 17 of the parish and Fabrique Act, no opposition to the civil recognition of the canonical decree has been filed with him, within the pescribed period of time; Whereas the formalities prescribed by said Act have been complied with and that it is expedient to issue a proclamation for the civil erection of said parislù Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council expressed in a decree bearing number 34, dated January 5th, 1955, and pursuant to the provisions of the parish and Fabrique Act, We have confirmed, establish and hereby confirm, establish, and recognize the limits and bounds set by the said canonical decree for the parish of Christ-Roi, in the Roman Catholic Diocese of Amos, as follows, to wit: A territory situate partly in the township of Dalquier and partly in the township of Figuery, all lots or parts thereof and present and future subdivisions thereof as well as roads, streets, lanes, railroad rights-of-way, streams, or parts thereof, included within the following limits, to wit: commencing at the point of intersection of the left or west bank of the Harricana River with the dividing line of ranges VI and VII, township of Figuery; thence, along the following lines and demarcations, successively; in the township of Figuery, with reference to the official cadastre for the said Township, the said line dividing ranges VI and VII, northwards; the dividing line of lots 6 ami 7, range VII; the dividing line of ranges VII and VIII, westwards; the westerly lateral line of lot 1, range VIII; the dividing line of ranges VIII and IX, eastwards; the dividing line of lots 9 and 10 of both ranges IX and X; the dividing line of the townships of Figuery and Dalquier, eastwards, with reference to the official cadastre for said township, the dividing line of lots 15 and 16 of each of the ranges I, II, III and IV; the dividing line of ranges IV and V, eastwards as far as the left bank or westerly bank of the Harricana River and finally, the said bank along the flow of the river in a slight westerly and southerly direction as far as the point of commencement; which territory shall be detached from the parish of Saint-Thérèse-d'Amos and shall be erected into a separate civil parish, under the name of parish of Christ-Roi, Diocese of Amos. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 277 Et Nous avons ordonné et déchiré et, par les présentes, ordonnons et déclarons (pie la paroisse de Christ-Roi, dans le diocèse catholique romain d'Amos, ci-haut décrite, sera une paroisse pour toutes les fins civiles.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent con-c erner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CP., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce dix-huitième jour de janvier en l'année mil neuf cent cinquante-cinq de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.' Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 39062-o ' JEAN BRUCHÉSI.Sièges sociaux And We have ordained and declared, and hereby ordain and declare that the parish of Christ-Roi, in the Roman Catholic Diocese of Amos, hereinabove described, shall be a parish for all civil purposes.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quehec/^this eighteenth day of January in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-five and in the third year of Our Reign.By Command, JEAN BRUCHÉSI, 39062 Under Secretary of the Province.Head Offices Beacon Enterprises Ltd.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Beacon Enterprises Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes émises par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, le 14 octobre 1953, et ayant son siège social en les cité et district de Montréal, a établi son bureau à No 5441 rue Hutchison, en les cité et district de Montréal.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, en la province de Québec, ce 10e jour de novembre 1953.Beacon Enterprises Ltd.Le Président, 39066 LUDWIG GUTH.Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal Avis est donné que la compagnie \"Bellini Shoe Co.Limited\", constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu de la Loi des compagnies de Québec en date du 29e jour de novembre 1954, a établi son siège social à 7213 rue Bcrri, Montréal, Que.Le Président, 39067 J.PEDULA.AVIS Le siège social de la compagnie \"J.Bastien & Fils Inc.\", est établi au numéro 182 de la rue Brière en la cité de Saint-Jérôme, dans le comté de Terrebonne.Saint-Jérôme, ce 4 janvier 1955.< * Le Secrétaire, 39068-o Signé: RENÉ BASTIEN.AVIS Avis est donné que \"Lalonde Motor Sales Rouyn-Noranda Ltd.\", constituée en corporation Beacon Enterprises Ltd.Notice is hereby given that \"Beacon Enterprises Ltd.\", incorporated by letters patent issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec on the 14th, October, 1953 and having its head office in the city and district of Montreal, has established its office at No.5441 Hutchison Street, in the city and district of Montreal.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company a being the Head Office of the Company.Dated at Montreal, in the Province of Quebec, this 10th day of November, 1953.Beacon Enterprises Ltd.LUDWIG GUTH, 39066-o President.Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal Notice is hereby given that \"Bellini Shoe'Co.Limited\", incorporated by letters paient under the Quebec Companies' Act.on the 29th day of November 1954, has established its head office at 7213 Bcrri Street, Montreal, Que.J.PEDULA, 39067-o President.NOTICE The Head Office of the company \"J.Bastien & Fils Inc.\", is established at number 182 Brière Street, in the City of Saint-Jérôme, County of Terrebonne.Saint-Jérôme, January 4th, 1955.(Signed) RENÉ BASTIEN, 39068 Secretary.NOTICE Notice is hereby given that \"Lalonde Motor Sales Rouyn-Noranda Ltd.\", incorporated by 278 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1956, Tome 87, N° 8 par lettres patentes en date du 4 octobre 1954, et ayant son bureau principal dans la cité de Noranda, Province de Québec, a établi son bureau au numéro 55, de la 9ième rue, dans ladite cité.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Noranda, ce 4 novembre 1954.Le Sécrétaire-t résorier, 390G9-o IVAN LALONDE.Main* Oka Mining Corporation (Xo Personal Liability) Avis est donné que la compagnie \"Main Oka Mining Corporation\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 21 décembre 1951, et ayant le principal siège de ses affaires à Montréal.Province de Québec, a établi son bureau à suite S10, lf>9 ouest, rue Craig, Montréal, Que.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté à Montréal, ce 29 décembre 1954.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier.39070-o RICHARD STAINES.Avis est donné que \"Yiau Limitée\", constitué par lettres patentes émises en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de la Province de Québec en date du 30 septembre 1930.a établi son siège social à 4945 est, rue Ontario, Montréal.Montréal, le 22 décembre 1951.(Sceau) Le Secrétaire, 390S8-o ABEL PAFARD.letters patent on the fourth day of October 1951, and having its head office in Noranda, Province of Quebec, has established its office at 55.ninth street, therein.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Noranda, this 4th dav of November 1954.IVAN LALONDE, 39009-o Secretary-Treasu rer.Main Oka Mining Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that \"Main Oka Mining Corporation\", company incorporated by letters patent dated the 21st of December 1954, ami having its chief place of business in Montreal, Province of Quebec, has established its office at Suite 810, 159 Craig Street West, Montreal, Que.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as< being the head office of the company.Montreal.December 29th.1954.(Seal) RICHARD STAINES, 39070-o Secretary-Treasurer.Notice is hereby given that \"Yiau Limitée\", incorporated by letters patent issued under Part I of the Province of Quebec Companies' Act on the 30th of September 1930.has established the Company' head office at 4945 Ontario East, Montreal.Montreal.December 22nd.1951.(Seal) ABEL FA FARD, 39088-o Secretary.Avis est donné que la Compagnie \"Ouellet & Arcand Inc.\" constituée en corporation par lettres patentes du 11 décembre 1954 et ayant son bureau-chef dans la cité de Québec, à établi son bureau au numéro 375rue Dorchester, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie son bureau principal.Donné à Québec, ce 13 janvier 1955.Le Secrétaire.39099-o CHARLES E.DESLAURIERS.Notice is hereby given that \"Ouellet & Arcand Inc.\", incorporated by letters patent dated December llth, 1954, and having its head office, in the city of Quebec, has established its office at 375 Dorchester Street, Quebec City.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Quebec, this 13th dav of January, 1955.CHARLES E.DESLAURIERS, 39099-o Sccretarv.Canada \u2014 Province de Québec District de Québec Bel-Tobe Shoe Company Limited Avis est donné (pie \"Bel-Tone Shoe Company, Limited\" constituée en corporation*par lettres patentes émises par le Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec en date du 13 avril 1948 et ayant son siège social en la cité de Québec, district de Québec, a transporté son bureau principal de Centre Industriel St-Malo, Québec, au N° 403 rue St-Yallier, est, Québec, district de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Québec, ce 19ièmc jour de janvier 1955.(Sceau) Le Secrétaire, 39107-o MAURICE BOULANGER C.A.Canada \u2014 Province of Quebec District of Quebec Bel-Tone Shoe Company Limited Notice is hereby given that \"Bel-Tone Shoe Company, Limited\", incorporated by letters patent issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec dated April 13th, 1948 and having its head office in the city of Quebec, district of Quebec, has transferred its head office from the St-Malo Industrial Center, Quebec, to No.463 St-Vallicr Street, East, Quebec, district of Quebec.From and after the dale of the present notice, the said office sh '.11 be considered by the Company as being its head office.Given at Quebec, this 19th dav of January, 1955.(Seal) MAURICE BOULANGER, C.A., 39107 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 279 Retone Incorporée Avis est par les présentes donné\u201eque la compagnie \"Retone Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du onze décembre mil neuf cent cinquante-trois, a établi son siège social au N° 45 rue McKinnon à Matane.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son principal bureau d'affaires.Donné à Matane, ce dix-septième jour de janvier mil neuf cent cinquante-cinq.(Sceau) 39100-o Retone Inc.Par le Secrétaire, G.ALEX LEBEL Retone Incorporée Notice is hereby given that \"Retone Inc.\", a company incorporated by letters patent bearing date the eleventh day of December, one thousand nine hundred and fifty-three, has established its Head Office at number 45 McKinnon Street, at Matane.On and from the date of this present notice, said office is considered by the company as being its principal place of business.Given at Matane, this seventeenth QUE, commerçant de St-' Pierre Lamy, comté de Témiscouata, demandeur, vs, JOSEPH PELLETIER, colon, Lamy, comté de Témiscouata, défendeur.\"Tous les droits que peut avoir ou qu'a Joseph Pelletier dans le lot, numéro 35, rang X, L.T.Seigneurie de Madawaska.Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.\" Pour être vendu MERCREDI le DEUXIÈME jour de FÉVRIER 1955 à DIX heures de l'avant-midi, à la porte de l'église de Lamy, comté de Témiscouata, P.Q.Le Shérif, Bureau du Shérif, P.E.MARTIN.Rivière-du-Loup, ce 21 décembre 1954.[Première insertion, vendredi le 31 décembre 1954] 38924-53-2-0 Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Kamouraska Cour de Magistrat, ( JOS E.LEVEILLÉ, mar-N?18898.< J chand de la cité de Ri-v vière-du-Loup, demandeur, vs, JOSEPH GIRARD, du même lieu, défendeur.\"Un terrain ou emplacement situé en la cité de Rivière-du-Loup, et faisant partie du lot numéro six cent onze-deux cent quatre-vingt-douze-deux (P.611-292-2) du cadastre officiel pour la ville de Fraserville, comté de Témiscouata, mesurant cent pieds (100'), mesure anglaise, sur chacun de ses côtés nord-est et sud-ouest, et cinquante pieds (50'), mesure anglaise, sur chacun de ses côtés sud-est et nord-ouest, et borné en front, au sud-est, à une lisière de terrain destinée à l'élargissement projeté du Chemin des Raymond et portant le numéro 611-96 du cadastre, vers le s.ud-ouest au terrain de Leopold Gagnon, vers le nord-ouest et vers le nord-est au résidu du terrain de la succession A.A.Fraser.Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.\" '.' Pouf 'être vendu à la porte de ¦l'église de la paroisse de St-Ludger de Rivière-du-Loup, MARDI le PREMD3R jour de FÉVRIER 1955 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, P.E.MARTIN.Rivière-du-Loup, ce 21 décembre 1954.[Première insertion, vendredi le 31 décembre 1954] 38923-53-2-0 KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Kamouraska Superior Court, (pt A MILLE J.LÈVES-No.19176.< \\J QUE, merchant of St.(Pierre Lamy, county of Témiscouata, plaintiff, vs, JOSEPH PELLETIER, settler, Lamy, county of Témiscouata, defendant.\"All rights which Joseph Pelletier has or may have to lot number 35, range X, L.T.Seigniory of Madawaska.All of which including buildings, erected thereon, circumstances and dependencies.\" To be sold WEDNESDAY, the SECOND day of FEBRUARY, 1955, at TEN o'clock in the afternoon, at the church door of Lamy, county of Témiscouata, P.Q.P.E.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Rivière-du-Loup, December 21st, 1954.[First insertion; Friday, December 31th, 1954.] 38924-53-2 Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Kamouraska Magistrate's Court, ( JOS E.LEVEILLÉ, mer-No.18898.< J chant of the city of (.Rivièrc-du-Loup, plaintiff, vs, JOSEPH GIRARD, same place, defendant.\"A piece of land or emplacement situated in the city of Rivière-du-Loup, and forming part of lot number six hundred and eleven, two hundred and ninety-two-two (P.611-292-2) of the official cadastre for the town of Fraserville, county of Témiscouata, measuring one hundred feet (100') English measure, on each of their northeasterly and southwesterly sides, and fifty feet (50'), English measure, on each of their southeasterly and northwesterly sides, and bounded to the front, southeasterly, by a strip of land destined for the proposed widening of the Raymond Road and bearing cadastral number 611-96, southwesterly by the land of Leopold Gagnon, northwesterly and northeasterly by the residue of land of the A.A.Fraser Estate.All of which with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.\" To be sold at the church door of the parish of St.Ludger de Rivière-du-Loup, TUESDAY, the FIRST day of FEBRUARY, 1955, at TWO o'clock in the afternoon.P.E.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Rivière-du-Loup, December 21st, 1954.[First insertion; Friday, December 31st, 1954] 38923-53-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.8 285 Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Quebec District de Kamouraska Cour de Magistrat, l T B.LAVOIE, avocat de N° 18678.< J \u2022 la cité de Rivière-du-I Loup, demandeur, vs, LORENZO CHAREST, de St-Mathias de Cabano, défendeur.\"Une maison bâtie sur le lot numéro huit (8) treize (13) du cadastre de la paroisse de St-Louis du Ha,.Ha, du village de Cabano.Tous les droits qu'il a ou peut avoir sur le lot huit treize (8-13) du cadastre de la paroisse de St-Loûis du Ha, Ha, du village de Cabano.\" Pour être vendue à la porte de l'église du village de Cabano, MERCREDI le DEUXIÈME jour de FÉVRIER 1955 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, P.E.MARTIN.Rivière-du-Loup, ce 21 décembre 1954.[Première insertion, vendredi le 31 décembre 1954] 38922-53-2-o ROUYN-NORANDA Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Rouyn-Noranda Cour Supérieure, l JOSEPH PHILIPPE COTÉ, N° 3377 < J agent distributeur domi-\\ cilié à Rouyn, et RENÉ BUISSON, agent distributeur, domicilié, également à Rouyn, demandeurs, vs DÉSIRÉ LESSARD, contracteur, domicilié à Granada, dit district, défendeur.Saisis comme appartenant au défendeur.\"Les droits acquis sur la demie nord du lot 7 rang III; la demie ouest de demie sud du lot 7 rang III; la demie nord de demie nord du lot 8 rang III, tous situés dans le canton Rouyn, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances\".Pour être vendus à la porte de l'église de St.Guillaume de.Granada, P.Q., le DEUXIÈME jour de FÉVRIER 1955, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.H.CHARBONNEAU.Rouyn, 22 décembre 1954.38920-53-2-o [1ère insertion le 31 décembre 1954) TÉMISCAMINGUE Fieri Facias de Terris Cour Supérieure, ( T^AME MARGUERITE N° 501 < ±J LEFEBVRE, veuve de \\ Réal Page de Fugèreville, district de Témiscamingue, tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice de son enfant Georges Henri Page, demanderesse, vs LÉONARD DOI-RE, cultivateur, «autrefois de Fugèreville susdit, maintenant de Ville-Marie, dans le district de Témiscamingue, défendeur.Saisis comme appartenant au défendeur: 1° Le lot de terre connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre, comme étant le numéro 1778 du cadastre pour.le village de Ville-Marie (lot 1778 cadastre Ville-Marie), avec les bâtisses dessus construites, appartenances et dépendances; 2° Le lot de terre connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour le canton Duhamel, comme étant les trois-quarts est du lot soixante-deux, rang trois, canton Du- Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Kamouraska Magistrate's Court, C T B.LAVOIE, attorney No.18678.< J \u2022 for the city of Rivière-\\ du-Loup, plaintiff, vs, LORENZO CHAREST, of St.Mathias de Cabano, defendant.\"A house erected on lot number eight (8) thirteen (13) of the cadastre of the parish of St.Louis du Ha, Ha, of the village of Cabano.With all rights which are or may be attached to lot eight thirteen (8-13) of the cadastre of the parish of St.Louis du Ha, Ha, village of Cabano.\" To be sold at the church door of the village of Cabano, WEDNESDAY, the SECOND day of FEBRUARY, 1955, at TWO o'clock in the afternoon.P.E.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Rivière-du-Loup, December 21st, 1954.[First insertion; Friday December 31st, 1954.] 38922-53-2 ROUYN-NORANDA Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Rouyn-Noranda Superior Court, I JOSEPH PHILIPPE COTÉ, No.3377 < J distributor agent dom-v iciled at Rouyn, and RENÉ BUISSON, agent distributor, also domiciled at Rouyn, plaintiff, vs DÉSIRÉ LESSARD, contractor, domiciled at Granada, said district, defendant.Seized as belonging to the defendant.\"The acquired rights on the north half of lot 7 range III; the west half of south half of lot 7 range III; the north half of north half of lot 8 range III, all situated in the Rouyn township, with the buildings thereon erected, circumstances and appurtenances\".To be sold at the church door of St.Guillaume de Granada, P.Q., the SECOND dav of FEBRUARY 1955, at TWO o'clock in the afternoon.J.H.CHARBONNEAU, Sheriff's Office, Sheriff.Rouyn, December 22nd, 1954.38920-53-2-o [1st insertion December 31st, 1954] TEMISCAMINGUE Fieri Facias de Terris Superior Court, /T^AME MARGUERITE No.501 -j LEFEBVRE, widow of v Réal Page fo Fugèreville, district of Témiscamingue, as much personally as in her quality of tutoress for her culd Georges Henri Page, plaintiff, vs LÉONARD DOIRE, farmer, heretofore of Fugèreville, above mentioned, presently of Ville-Marie, in the district of Témiscamingue, defendant.Seized as belonging to the defendant : 1.Lot of land known and designated on the official plan and in the book of reference of the cadastre as being number 1778 of the.cadastre for the village of Ville-Marie (lot 1778 cadastre Ville-Marie), with buildings thereon erected, appurtenances and dependencies; 2.Lot of land known and designated on the official plan and in the book of reference of the cadastre for the Duhamel township, as being the easterly three-quarter part of lot sixty- 286 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 22 janvier 1955, Tome 87, N° S hainel (^cst, lot 62 rang 3 Duhamel) avec les two, range three, Duhamel township (easterly bâtisses dessus construites appartenances et dé- % part, lot 62, range 3 Duhamel) with the pendanecs, lesquels dits lots sont en la posses- buildings^ thereon erected, appurtenances and sion de Léonard Doire, cultivateur de Ville- dependencies, the said lots are in the possession Marie, comme lui appartenant.of Léonard Doire, farmer of Ville-Marie, as belonging to him.I Pour être vendus à la porte de l'église parois- To be sold at the parochial church door of siale de Notre-Dame du Rosaire de Ville-Marie, Notre-Dame du Rosaire of Ville-Marie, WED- MERCREDI le DEUXIÈME jour de FÉ- NESDAY, the SECOND day of FEBRUARY, VRIER 1955, à DIX heures de l'avant-midi.1955, at TEN o'clock in the forenoon.Le Shérif, JULES GRENIER, Bureau du Shérif, JULES GRENIER.Sheriff's Office, Sheriff.Ville-Marie, le 22 décembre 1954.38921-53-2-0 Ville-Marie, December 22nd, 1954.38921-53-2 [Première insertion le 31 décembre 1954] [First insertion December 31st, 1954] Index de la Gazette officielle de Québec, N° 3 Action en séparation de biens: Gordon vs Magid.244 Arrêtés en Conseil: 1216 \u2014 Concernant le brûlage des abatis et des débris forestiers.256 1217 \u2014 Concernant la circulation en forêt.;.250 1218 \u2014 Concernant les scieries en forêt 251 1227 \u2014 Concernant l'exécution de travaux en forêt.253 20 \u2014 Épiciers et bouchers de Sherbrooke.250 21 \u2014 Industrie et métiers de la construction dans la région de Montréal.250 22 \u2014 Métiers de barbier et de coiffeur dans la région de Montréal.247 25-c \u2014 Métiers de barbier, dcoiffeur et coiffeuse dans le comté de Chicoutimi 244 25-F \u2014 Comité paritaire des barbiers, coiffeurs et coiffeuses, juridiction de Chicoutimi.249 Avis aux intéressés: Avis divers: Brinton Realty Corp.(Directeurs) .:.259 Hôpital Comtois, Inc.(Règlement).258 La Caisse'Populaire du Petit Séminaire de St-Georgcs, Beauce (Fondation).258 Les Entreprises de Terrazzo, Marbre et Tuile Ltée (Directeurs).257 Les Entreprises Pyramides Limitée (Directeurs).260 Ormstown War Memorial Community Centre Inc.(Directeurs).258 Périni Québec Inc.(Correction).259 Pointe Claire Civic Action League (Directeurs) .258 Syndicat Catholique des Employés de Magasins de Magog (Fondation).257 Trans-Canada Film Distributors Corp.(Directeurs).258 Chartes \u2014 Abandon de: Bramhorn Inc.\u2022.259 Crabtree & Company Ltd.259 Randall Realties Inc.260 W.B.Realty Company.260 Compagnie autorisée à faire des affaires: Friedrich Refrigerators Incorporated .260 Index of the Quebec Official Gazette, No.3 Action for Separation as to Property: Gordon vs Magid.244 Orders in Council: 1216 \u2014 Concerning the burning of slash and forest debris.256 1217 \u2014 Concerning travelling in forests 250 1218 \u2014 Concerning saromills in forests 251 1227 \u2014 Concerning the carrying out of operations in the forest.253 20 \u2014 Grocers and butchers of Sherbrooke.250 21 \u2014 Construction industry and trades in the region of Montreal.250 22 \u2014 Barber and hairdresser trades in the region of Montreal.247 25-c \u2014 Barber and hairdressing trades in the county of Chicoutimi.244 25-F \u2014 Barbers and Hairdressers Parity Committee, jurisdiction of Chicoutimi 249 183 Miscellaneous Notices: Brintom Realty Corp.(Directors).259 Hôpital Comtois, Inc.(By-Law).258 La Caisse Populaire du Petit Séminaire de St-Georges, Beauce (Foundation) 258 Les Entreprises de Terrazzo, Marbre et Tuile Ltée (Directors).257 Les Entreprises Pyramides Limitée (Directors).260 Ormstown War Memorial Community Centre Inc.(Directors).258 Périni Québec Inc.(Correction).259 Pointe Claire Civic Action League (Directors) .258 Syndicat Catholique des Employés de Magasins de Magog (Formation).257 Trans-Canada Film Distributors Corp.(Directors).258 Charters \u2014 Surrender of: Bramhorn Inc.259 Crabtree & Company Ltd.259 Randall Realties Inc.260 W.B.Realty Company.260 Company Licensed to do Business: Friedrich Refrigerators Incorporated .260 183 Notice to Interested Parties: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 22nd, 1955, Vol.87, No.3 287 Compagnies dissoutes: Karrys' Recreation Academy, Ltd.260 Mac Holdings Inc.261 Page Construction (Québec) Limitée .261 The Acme Realty Co.261 Curatelle publique: Succession Henri Doucet.261 Demandes à la Législature: Corporation des courtiers d'assurance de la province de Québec.262 Dorval, ville de.s 262 Drummondville, cité de.264 Duhamel, Joseph et al.265 La Corporation de l'École Polytechnique .-.263 Le Palais du Commerce Incorporé \u2014 (Show-Mart Incorporated).264 Paul, Irving-Louis et al.263 Pointe-Claire, ville de.262 Prud'homme, Luc, sr.et al.264 Succession Hon.Tréfilé Berthiaume\u2014 262 DÉPARTEMENTS \u2014 AVIS DES : Agriculture: Industrie laitière: Ordonnance N° 7-55 \u2014 Rivière-du-Loup 266 Ordonnance N° 37-55 \u2014 Bas St-Laurent 267 Instruction publique: Municipalité scolaire de: Arthabaska, ville de.268 Dubois.268 Ely-Ouest.268 St-Aubert.268 St-Joseph-de-Coleraine.268 St-Aubert.268 St-Damase-de-LTslet.268 St-Gabriel-de-Brandon, paroisse de.269 Terres et Forêts: Service du Cadastre : Mazenod, canton de.269 Travail: Industrie ou métiers de: Commerce de détail dans la cité de Chicoutimi (Modification).269 Verre dans la région de Québec (Modification).
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.