Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 26 mars 1955, samedi 26 (no 12)
[" Tome 87, N° 12 995 Vol.87, No.12 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.eh.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 26 mars 1955 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, March 26th, 1955 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 996 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1965, Tome 87, N° 12 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: S7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante:.Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.38933 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to thejnch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.38933 \u20141-52 Lettres patentes (P.G.1038S-55) Bentwood Chairs Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinzième jour de février 1955, constituant en corporation: Eli Michael Berger, John Li-berman, Moses Moscovitch, avocats et Rhoda Cohen, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de meubles, sous le nom de \"Bentwood ('hairs Co.\", avec un .capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quinzième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, ' 39475 \u2022 C.E.CANTIN.Letters Patent (A.G.10388-55) Bentwood Chairs Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February, 1955, incorporating: Eli Michael Berger, John Liberman, Moses Moscovitch, advocates, and Rhoda Cohen, secretary, fille majeure usant de ses droits, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in furniture, under the name of \"Bent-wood Chairs Co.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of S100 each and into 200 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 997 (P.G.10350-55) Branson .Construction Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onzième jour de février 1955, constituant en corporation: Philip Henry Braendel Jr., William Eugène Braendel et Hcndrick Renou, tous constructeurs, de Lachine, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Diriger et exercer le commerce de constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de \"Branson Construction Company\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 700, 47e avenue, Lachine, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce onzième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(P.G.10170-55) Carrière Bernier Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de QuébVc, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre février 1955, constituant en corporation: Philodor Ouimet, Réal Ouimct et Jean-Guy Ouiniet, tous industriels, de la paroisse de Saint-Jean l'Évangéliste, district judiciaire d'Iber-ville, pour les objets suivants: Faire affaires comme carriers, sous le nom de \"Carrière Bernier Ltée\", avec vin capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur général, le quatre février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(P.G.10415-55) Classic's Little Books Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinzième jour de février 1955, constituant en corporation: Eli Michael Berger, John Liber-man, avocats et Rhoda Cohen, secrétaire, fille majeure, usant de ses droits, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Publier, éditer et distribuer des livres, revues et périodiques, sous le nom de \"Classic's Little Books Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quinzième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(P.G.10340-55) Club Aramis Inc.(A.G.10350-55) Branson Construction Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of February, 1955, incorporating: Philip Henry Braendel Jr., William Eugene Braendel and Hendrik Renou, all builders, of Lachine, judicial district of Montreal, for the following purposes: To conduct and carry on the business of builders and contractors, under the name of \"Branson Construction Company\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 700, 47th Avenue, Lachine, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-o Deputy Attorney General.(A.G.10170-55) Carrière Bernier Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of February, 195Ô, incorporating: Philodor Ouimet, Real Ouimet, and Jean-Guy Ouimet, all industrialists, of the parish of Saint-Jean l'Évangéliste, judicial district of Iberville, for the following purposes: To carry on business as quarriers, under the name of \"Carrière Bernier Ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-John, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(A.G.10415-55) Classic's Little Books Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February, 1955, incorporating: Eli Michael Berger, John Liberman, advocates, and Rhoda Cohen, secretary, fille majeure usant de ses droits, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To publish, edit and distribute books, magazines and periodicals, under the name of \"Classic's Little Books Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General.(A.G.10340-55) Club Aramis Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième Notice is hereby given that under Part III of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have 998 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre février 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Marcel Nichols, avocat, Lucienne Pinard, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, et Roland L'Étoile, bijoutier, tous de Drummondville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Former et maintenir un Club pour l'amusement et le divertissement de ses membres, sous le nom de \"Club Arainis Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de 8200,000.Le siège social de la corporation sera à 414, rue Lindsay, Drummondville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le quatre février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(P.G.10322-55) Daymor Dress Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorze février 1955, constituant en corporation: Max Schwartz, manufacturier, Alan Golden, commis et Bernard Diamond, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de robes, vêtements de sport et articles vestimentaires de toutes sortes, sous le nom de \"Daymor Dress Inc.\", avec un capital total de $40.000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions priviliées de $100 chacune.Lé siège social de la compagnie sera à 395 rue Mayor, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le.quatorze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(P.G.10196-55) Dupéré Frères Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre février 1955, constituant en corporation: Abraham Dupéré, marchand de quincaillerie, Maria-Anna-Alcxandra Bleau-Dupéré, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Abraham Dupéré, efdûment autorisée par lui aux fins des présentes, Ludger Dupéré, marchand de quincaillerie, et Marie-Yvette Gauthier-Dupéré, ménagère, épouse con-tractuellement séparée de biens dudit Ludger Dupéré, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de meubles, boiseries, ornements, outillages, ameu-meublement, machineries, appareils électriques, jouets, ferronnerie, quincaillerie, nouveautés et articles de tous genres, sous le nom de \"Dupéré Frères Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Lç siège social de la compagnie sera à 9670, rue Notre-Dame est, Montréal, district judiciaire de Montréal.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of February 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Marcel Nichols, advocate, Lucienne Pinard, secretary, fille majeure making use of her rights, and Roland L'Étoile, jeweller, all of Drummondville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes : To form and maintain a Club for the amusement and recreational activities of its members, under the name of \"Club Aramis Inc.\".The amount to which the value of the immoveable propertv which the corporation may hold is to be limited, is $200,000.The head office of the corporation will be at 414 Lindsay Street, Drummondvillc, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of February 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(A.G.10322-55) Daymor Dress Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1955, incorporating: Max Schwartz, manufacturer, Alan Golden, clerk, and Bernard Diamond, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in dresses, sportswear and clothing of all kinds, under the name of \"Daymor Dress Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 395 Mayor Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-o Deputy Attorney General.(A.G.10196-55) Dupéré Frères Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of February, 1955, incorporating: Abraham Dupéré, hardware merchant, Maria-Anna-Alexandria Bleau-Dupéré, ^housekeeper, wife contractually separate as to property of the said Abraham Dupéré, and duly authorized by him for these present purposes, Ludger Dupéré, hardware merchant, and Marie-Yvette Gauthier-Dupéré, housekeeper, wife contractually separate as to property of the said Ludger Dupéré, and duly authorized by him for these present purposes, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture, woodwork, ornaments, equipment, house furnishings, machinery, electrical appliances, toys, ironware, hardware, novelties and articles of all kinds, under the name of \"Dupéré Frères Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 9670 Notre-Dame Street-East, Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 999 Daté du bureau du Procureur général, le quatre février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(P.G.10348-55) F.W.Peel, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorzième jour de février 1955, constituant en corporation: Robert Harold Earle Walker, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Montréal, William Tetley et Charles A.Phclan, avocats, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à négocier, préparer et assister à la mise à exécution de transactions d'achat, de vente, de location ainsi que celui qui consiste à nantir, hypothéquer, charger et exécuter toutes autres dispositions de propriétés rçelles et personnelles et de droits d'aucune sorte, sous le nom de \"F.W.Peel, Limited\", avec un capital total de S10,000, divisé en 10,000, actions de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1117 ouest, rue Ste-Catherinc, ehambre 524, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatorzième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(P.G.10367-55) Garccau, Perrcault & Garccau, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze février 1955, constituant en corporation: Placide Perreault, entrepreneur de pompes funèbres, de Saint-Jacques de Montcalm, Grégoire Garceau, entrepreneur de pompes funèbres, Gisèle Laurin, ménagère, épouse de Grégoire Garceau, de Juliette, tous du district judiciaire de Joliettc, et Albert Ménard, bourgeois, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses ramifications les fonctions de directeurs de funérailles, sous le nom de \"Garceau, Perreault & Garccau, Inc.\", avec un capital total de 899,900, divisé en 699 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 636, rue Manseau, Joliette, district judiciaire de Juliette.Daté du bureau du Procureur général, le quinze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(P.G.10320-55) Gardicore Uranium Corporation (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onzième jour de février 1955, constituant en corporation: Marcel Lajeunesse, Jean-Paul Cardinal, Jacques-Paul Dansereau, avocats, de Montréal, Lovell C.Carroll, avocat, C.R., de Dated at the office of the Attorney General» this fourth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(A.G.10348-55) F.W.Peel, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1955, incorporating: Robert Harold Earle Walker, advocate and Queen's Counsel, of Montreal, William Tetley and Charles A.Phelan, advocates, of the town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of negotiating, arranging for and assisting in the carrying out of the purchase, sale, leasing, mortgaging, hypothecating, charging or other disposal of real and personal property and rights of all kinds, under the name of \"F.W.Peel, Limited\", with a total capital stock of S 10,000, divided into 10,000 shares of SI each.The head office of the company will be at 1117 St.Catherine St.West, Room 524, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-o Deputy Attorney General.(A.G.10367-55) Garceau, Perreault & Garceau, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February 1955, incorporating: Placide Perreault, undertaker, of Saint-Jacques de Montcalm Grégoire Gardeau, undertaker, Gisèle Laurin, housewife, wife of Grégoire Gardeau, of Joliette, all of the judicial district of Joliette, and Albert Ménard, gentleman, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on, in all its branches, the business of undertakers, under the name of \"Garceau, Perreaidt & Garceau, Inc.\", with a total capital of 899,900, divided into 699 common shares of a par value of SI00 each and 300 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be,at 636 Manseau Street, Joliette, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(A.G.10320-55) Gardicore Uranium Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of February, 1955, incorporating: Marcel Lajeunesse, Jean-Paul Cardinal, Jacques-Paul Dansereau, advocates, of Montreal, Lovell C.Carroll, advocate, Q.C., of 1000 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 ville Mont-Royal et Denise Jalbert, secrétaire, fille majeure, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Gardicore Uranium Corporation (No Personal Liability), avec un capital total de $5,000,000, divisé en 5,000,000 d'actions ordinaires de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce onzième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(P.G.10270-55) Georges Planiondon Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze février 1955, constituant en corporation: Georges Plamondon, industriel, Jules Sirois, C.A., comptable, et Antoine Biron, C.R., avocat, tous de Drummondville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de liqueurs et breuvages non alcoolisés, sous le nom de \"Georges Plamondon Ltée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 250 actions communes de $100 chacune et en 750 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera rue Brock, Drummondville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le douze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 ^ C.E.CANTIN.the town of Mount Royal, and Denise Jalbert, secretary, spinster of the full age of majority, of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals and deal with same, tinder the name of \"Gardicore Uranium Corporation\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $5,000,000 divided into 5,000,000 common shares of a par value of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General.(A.G.10276-55) Georges Plamondon Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of February, 1955, incorporating: Georges Plamondon, industrialist, Jules Sirois, C.A., accountant, and Antoine Biron, Q.C., advocate, all of Drummondville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To manufacture and deal in soft drinks and non-alcoholic beverages, under the name of \"Georges Plamondon Ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 250 common shares of $100 each and into 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Brock Street, Drummondvillc, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(P.G.10351-55) Glcndalc Fur Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorzième jour de février 1955, constituant en corporation: Joseph Katzof, fourreur, Rose Gross Katzof, ménagère, épouse séparée de biens de Joseph Katzof, tous deux de Montréal et Morris Galet, marchand, d'Outrcmont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de fourrures, pelleteries, vêtements de fourrure et articles vestimentaires de toutes sortes, sous le nom de \"Glendale Fur Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 154 ouest, rue Ste-Cathcrine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatorzième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(A.G.10351-55) Glendale Fur Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1955, incorporating: Joseph Katzof, furrier, Rose Gross Katzof, housewife, wife separate as to property of Joseph Katzof, both of Montreal, and Morris Galct, merchant, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in furs, pelts, fur garments and wearing apparel of every kind, under the name of \"Glendale Fur Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 154 St.Catherine Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 30475-O Deputy Attorney General, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 1001 (P.G.10193-55) Intcrstute Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seizième jour de février 1955, constituant en corporation: Aline Salomon, rentière, veuve non remariée de feu Herman Salomon, Steven Stenge vendeur et Jeanne-Françoise Raymond, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Interstate Investment Corporation\", avec un capital total de 800,000, divisé en 10 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 590 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(P.G.10341-55) Irval Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du septième jour de février 1955, constituant en corporation: Dov Kravetz, étudiant en droit Meta Henry, secrétaire, et Sarah Miller, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de robes, vêtements de sport, lingerie et accessoires, sous le nom de \"Irval Inc.\", avec un capital total de 8500 divisé en 500 actions de 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(P.G.10215-55) J.A.Gossclin Sales Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept février 1955, constituant en corporation: Robert Bernard, industriel, Antoine Biron, C.R., avocat, tous deux de Drummondville, et Fer-nand Beaudoin, gérant, de Drummondville-Ouest, tous du district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Exercer le commerce de matières premières, de produits manufacturés, de machines, de machineries, d'outils, d'instruments ou de tous accessoires ou parties d'iceux, sous le nom de \"J.A.Gosselin Sales Ltd.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 100 actions communes de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Drummondville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le sept février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(A.G.10193-55) Interstate Investment Corporation Notice is hereby given thaf under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of February, 1955, incorporating: Aline Salomon, annuitant, unremarried widow of the late Herman Salomon, Steven Stenge, salesman, and Jeanne-Françoise Raymond, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the.following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Interstate Investment Corporation\", with a total capital stock of 860,000, divided into 10 common shares of a par value of 8100 each and into 590 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General.(A.G.10341-55) Irval Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of February, 1955, incorporating: Dov Kravetz, studcnt-at-Law, Meta Henry, secretary, and Sarah Miller, stenographer, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in dresses, sportswear, lingerie and accessories, under the name of \"Irval Inc.\", with a total capital stock of $500, divided into 500 shares of SI each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General.(A.G.10215-55) J.A.Gosselin Sales Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of February 1955, incorporating: Robert Bernard, industrialist, Antoine Biron, Q.C., advocate, both of Drummondville, and Fernand Beaudoin, manager, of Drummondville-West, all of the judicial district of Arthabaska, for the following purdoscs: To deal in raw materials, manufactured products, machinery, tools, instruments, and any accessories or parts thereof, under the name of \"J.A.Gosselin Sales Ltd.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 100 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at Drummondville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General, 1002 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 (P.G.13232-54) Joan Films Transport Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un janvier 1955, constituant en corporation: Jean-Simon Fortin, hôtelier, Raymond Otis, homme d'affaires, et Germaine Schmitt Otis, ménagère, épouse séparée de biens dudit Raymond Otis, tous de Dolbeau, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Faire dans toutes ses branches les affaires de transport en général et plus particulièrement le transport de films et de tout matériel servant à l'industrie cinématographique, sous le nom de \"Joan Films Transport Ltée\", avec un capital total de S10,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Dolbeau, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un janvier 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(Sec.P.189-55) La Compagnie d'Assurance du Club des Automobilistes de Montréal Montreal Automobilists' Club Insurance Company Avis est par les présentes donné qu'en vertu des articles 2 et suivants de la Loi des assurances de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huitième jour de mars 1955, constituant en corporation : Laurent La-belle, industriel, Paul-Émile Ménard, gérant, Henri Gareau, comptable, 'J.-Édouard Jcan-notte, notaire, Jean Trudel, avocat, conseil en loi de la Reine, pour les objets suivants: Réaliser des opérations d'assurance et de réassurance terrestre, maritime, aérienne, sauf l'assurance ou la réassurance sur la vie; Se porter caution, y compris caution en justice; Sans restreindre la portée des pouvoirs ci-dessus mentionnés, réaliser des opérations d'assurance ou de réassurance suivantes: contre les accidents, d'automobiles, d'aviation, contre le vol avec ou sans effraction, de crédit, contre les explosions, contre l'indendie, contre le faux, de garantie, de fidélité, contre la grôle, industrielle, responsabilité civile, navigation intérieure, transport, maritime océanique, contre le bris de glace (plate-glass), contre la maladie, contre les défectuosités d'extincteurs automatiques, sur les chaudières à vapeur, contre les cyclones, les intempéries, ou tout autre genre d'assurance ou de réassurance, excepté l'assurance-vie; Réaliser toutes opérations et conclure tous contrats nécessaires ou utiles à la poursuite de ses affaires; Le tout dans les limites fixées par la Loi des assurances de Québec, sous le nom de \"La Compagnie d'Assurance du Club des Automobilistes de Montréal \u2014 Montreal Automobilists' Club Insurance Company\", avec un capital de cinq cent mille dollars (8500,000.) divisé en cinq mille (5,000) actions ordinaires de cent dollars ($100.) chacune.Le bureau principal de la compagnie sera à Montréal, dans le district de Montréal.Lesdites lettres patentes seront en vigueur à compter de la date de l'émission (l'un permis (A.G.13232-54) Joan Films Transport Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of January, 1955, incorporating: Jean-Simon Fortin, hotel-keeper, Raymond Otis, businessman, and Germaine Schmitt Otis, housekeeper, wife separate as to property of the said Raymond Otis, all of Dolbeau, judicial district of Roberval, for the following purposes: To carry on in all its branches, a general transportation business and especially the transportation of films and of all material used in the moving-picture business, under the name of \"Joan Films Transport Ltée\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Dolbeau, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of January, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(P.Sec.189-55) < La Compagnie d'Assurance du Club des Automobilistes de Montréal Montreal Automobilists' Club Insurance Company Notice is hereby given that under sections 2 and following of the Quebec Insurance Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the province of Quebec, dated the eighth day of March 1955, incorporating: Laurent Labelle, industrialist, Paul Emile Ménard, manager, Henri Garcau, accountant, J.Edouard Jeannotte, notary, Jean Trudel, advocate, Queen's Counsel, for the following purposes.To transact the business of terrestrial, marine and aviation insurance and reinsurance, except life insurance and reinsurance; To act as surety, including judicial surety; Without restricting the scope of the above mentioned powers, to undertake the business of insurance and reinsurance of the following classes: accident, automobile, aviation, larceny, housebreaking or burglary, credit, explosion, fire, forgery, guarantee, hail, industrial, public liability, inland marine, inland transportation, livestock, ocean marine, plate glass, sickness, sprinkler leakage, steam boiler, tornado, weather, and any other class of insurance and reinsurance, except life insurance; To carry out any operations and make any other contracts necessary for the conduct of its business; 0 The whole within the scope of the limits fixed by the Quebec Insurance Act, under the name of \"La Compagnie d'Assurance du Club des Automobilistes de Montréal \u2014 Montreal Automobilists' Club Insurance Company\", with a capital stock of five hundred thousand dollars ($500,000.) divided into five thousand (5,000) ordinary shares of a par value of one hundred dollars ($100.) each.The head office of the company will be at Montreal, in the district of Montreal.The letters patent shall come into force as from the date of issue of la license to the com- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1956, Vol.87, No.12 1003 à la compagnie en vertu de la Loi des assurance de Québec.Daté du bureau du Procureur général, ce quatorzième jour de mars 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(P.G.10154-55) La Compagnie d'Excavation \u2022 Santerrc Limitée Santerre Excavation Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un janvier 1955, constituant en corporation: David Santerre, entrepreneur, de l'Ile Perrot, Benoit Gauthier, avocat, de Montréal, et Roger Picard, comptable, de ville Jacques-Cartier, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux, constructeurs et excavateurs, sous le nom de \"La Compagnie d'Excavation Santerre Limitée \u2014 Santerre Excavation Company Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 40, Boulevard Denault, Ile Perrot, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un janvier 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(P.G.10253-55) La Ferronnerie de Rimouski Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre février 1955, constituant en corporation: Aldéric Laurendeau, C.R., Godefroy Lau-rendeau, avocats, d'Outremont, et Juliette Bélanger, secrétaire, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de ferronnerie, quincaillerie et matériaux de construction, sous le nom de \"La Ferronnerie de Rimouski Inc.\", avec un capital total de $125.000, divisé en 350 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le quatre février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(P.G.10336-55) Lampert & Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinze février 1955, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, d'Outremont, Bernard Diamond, avocat, Alan Golden, commis, tous deux de Montréal, Egbert Cockerton, avocat, de St-Hubert, tous du district judieiaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de marchandises sèches, sous le nom de \"Lampert pany under the Quebec Insurance Act.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of March, 1955.C.E.CANTIN, 39475-o Deputy Attorney General.(A.G.10154-55) La Compagnie d'Excavation Santerrc Limitée Santerrc Excavation Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of January, 1955, incorporating: David Santerre, contractor, of He Perrot, Benoit Gauthier, advocate, of Montreal, and Roger Picard, accountant, of the town of Jacques-Cartier, all of the judicial district of Montreal for the following purposes: To carrj' on business as general contractors, builders and excavators, under the name of \"La Compagnie d'Excavation Santerre Limitée \u2014 Santerre Excavation Company Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 commons shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 40, Denault Boulevard, He Perrot, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of January, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(A.G.10253-55) La Ferronnerie de Rimouski Inc.> Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of February, 1955, incorporating: Aldéric Laurendeau, Q.C., Godefroy Laurendeau, advocates, of Outremount, and Juliette Bélanger, secretary, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in ironmongery, hardware and building materials, under the name of \"La Ferronnerie de Rimouski Inc.\", with a total capital stock of $125,000, divided into 350 common shares of a par value of $100 each and 900 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Rimouski, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(A.G.10336-55) Lampert & Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February, 1955, incorporating: Louis Orenstein, advocate, of Outreraont, Bernard Diamond, advocate, Alan Golden, clerk, both of Montreal, Egbert Cockerton, advocate, of St.Hubert, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in dry goods, under the name of \"Lambert & Co.Ltd.\", with a total 1004 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Qttêbec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 & Co.Ltd.\", avec un capital total de §40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C E.CANTIN.(P.G.10197-55) Les Lut reprises Dupéré Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre février 1955, constituant en corporation: Abraham Dupéré, marchand de quincaillerie, Maria-Anna-Alexandra Blcau Dupéré, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Abraham Dupéré, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Ludger Dupéré, marchand de quincaillerie, et Marie-Yvette Gauthier Dupéré, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Ludger Dupéré, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Les Entreprises Dupéré Ltée\", avec un capital total de 8-10,000, divisé en 4,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 9670, rue Notre-Dame, est, Montreal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General.(A.G.10197-55) Les Entreprises Dupéré Liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of February, 1955, incorporating: Abraham Dupéré, hardware merchant, Maria-Anna-Alexandra Blcau Dupéré, housekeeper, wife contractually separate as to property of the said Abraham Dupéré, and duly authorized by him for these present purposes.Ludger Dupéré, hardware merchant, and Marie-Yvette Gauthier Dupéré, housekeeper, wife contractually separate as to property of the said Ludger Dupéré, and duly authorized by the latter for these present purposes, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate under the name of \"Les Entreprises Dupéré Ltée\", with a total capital stock of 840,000.divided into 4,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at 9670 Notre-Dame Street-East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(P.G.1020S-55) Les Loisirs Notre-Dame-des-Neiges Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze février 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Adrien Desforges, entrepreneurs-peintre, Henri Boudrias, gérant pour Ryder Machinery, Maurice Normandin, employé civique, Donald MacDonald, commis des chemins de fer, Frère Gérard Trudcl, c.s.c, Frère Gaston Hamelin, c.s.c, Jean Huberdeault, instituteurs, Bernard Rousseau, marchand de fourrures, Roger Robillard, bijoutier, Raymond Lauzon, employé pour (îurney, René Bernard, employé commission de transport, Guy M iron, comptable, et Edouard Marenger, employé de laboratoire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Travailler à l'organisation fies loisirs dans la paroisse Notre-Dame-des-Neigcs, sous le nom de \"Les Loisirs Notre-Dame-dcs-Neiges\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 8250,000.Le siège social de la corporation sera à 5307, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 Ç, E, CANTIN, (A.G.10208-55) Les Loisirs Notrc-Damc-des-Nciges Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Adrien Desforges, master-painter, Henri Boudrias, manager for Ryder Machinery, Maurice Normandin, civic employee, Donald MacDonald, railroad clerk, Brother Gérard Trudel, C.H.C., Brother Gaskon Hamelin, C.H.C., Jean Huberdeault, teachers, Bernard Rousseau, fur merchant, Roger Robillard, jeweller, Raymond Lauzon, Gurney employee, René Bernard, employee of Transnort Commission, Guy Aliron, accountant, and Edouard Alarenger, laboratory employee, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: Endeavour to organize recreational activities in the parish of Notre-Dame-des-Neiges, under the name of \"Les Loisirs Notre-Dame-des-Neiges\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 8250,000.The head office of the corporation will he at 5307 Côte des Neiges Road, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 20th, 1955, Vol 87, No.12 1005 (P.G.10343-55) Les Placements du Cap Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit février 1955, constituant en corporation: Camil Noël, c.r., avocat, Claude Rioux, avocat, et Françoise Lemay, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Les Placements du Cap Inc.\", avec un capital total de §150,000, divisé en 000 actions ordinaires de S100 chacune et en 900 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 25, rue Dorchester, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le huit février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(P.G.10071-55) Mars Finance Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze février 1955, constituant en corporation: Gérard Gauthier, commerçant, de Jon-quière, ' Pierre Beaulieu, agent d'assurances, Fernand Perron, comptable, J.-Baptiste A.Gagnon, agent-manufacturier, et Jean-Paul Tremblay, commerçant, ces quatre derniers de Chicoutimi, tous du district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de prêteur d'argent, sous le nom de \"Mars Finance Inc.\", avec un capital total de 8500,000, divisé en 1,050 actions ordinaires de 8100 chacune et en 3,350 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 31, rue Racine, ouest, Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(P.G.10178-55) Matane Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du huit février 1955, constituant en corporation: Paul-Emile Gagnon, J.-Claude Gagnon, avocats, et Lucienne Michaud, secrétaire, fille majeure et usant de ses droits, tous des cité et district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Matane Construction Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions d'une valeur nominale de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Matane, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le huit février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C, E, CANTIN.(A.G.10343-55) Les Placements du Cap Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of February 1955, incorporating: Camil Noël, Q.C., advocate, Claude Rioux, advocate, and Françoise Lemay, secretary, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the operations of an investment company, under the name of \"Les Placements du Cap* Inc.\", with a total capital of 8150,000.divided into 000 common shares of 8100 each and 900 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 25 Dorchester Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(A.G.10071-55) Mars Finance Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1955, incorporating: Gérard Gauthier, dealer, of Jonquière, Pierre Beaulieu, insurance agent, Fernand Perron, accountant, J.Baptiste A.Gagnon, manufacturing agent, and Jean-Paul Tremblay, dealer, the latter four from Chicoutimi, all of the judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on the general business of a money lender, under the name of \"Mars Finance Inc.\", with a capital stock of 8500,000, divided into 1,050 common shares of $100 each and into 3,350 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 31, Racine Street, West, Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this jourtcenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(A.G.10178-55) Matane Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of February, 1955, incorporating: Paul-Emile Gagnon, J.-Claude Gagnon, advocates, and Lucienne Michaud, secretary, spinster in use of her rights, all of the city and judicial district of Rimouski, for the following purposes: To carry on the operations of a construction company under the name of \"Matane Construction Ltd.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 400 shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company will be at Matane, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this eight day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General. 1006 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 (P.G.10217-55) M.C.Schrank (Canada) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinze février 1955, constituant en corpora-' tion: Joseph Helal, Royal Werry, avocats et conseils en loi de la Reine, et Samuel Berger, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'habits et vêtements, sous le nom de \"M.C.Schrank (Canada) Limited\", avec un capital total de §100,000, divisé en 500 actions ordinaires de S100 chacune et 500 actions privilégiées de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(A.G.10217-55) M.C.Schrank (Canada) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February, 1955, incorporating: Joseph Helal, Royal Werry, advocates and Queen's Counsel, and Samuel Berger, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing and wearing apparel, under the name of \"M.C.Schrank (Canada) Limited\", with a total capital stock of §100,000, divided into 500 common shares of §100 each and into 500 preferred shares of §100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General,\" this fifteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General.(P.G.10285-55) M inlo Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinzième jour de février 1955, constituant en corporation: Théophile Bouziane, industriel, Albert Shohet, constructeur et Joseph Saul Mooallim, marchand, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets sui-cants: Entreprendre le commerce de la construction, sous le nom de \"M into Enterprises Ltd.\", avec un capital total de §100,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de §1 chacune et 8,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 232 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quinzième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(P.G.10349-55) Miss Susan Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorze février 1955, constituant en corporation: Frank F.Hubscher, avocat, Donald Kujan, étudiant et Leona Green, teneuse de livres, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de vêtements, sous le nom de \"Miss Susan Inc.\", avec un capital total de 810.000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN, (A.G.10285-55) Minto Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February, 1955, incorporating: Théophile Bouziane, industrialist, Albert Shohet, builder and Joseph Saul Mooallim, marchand, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To engage in the construction business, under the name of \"Minto Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of S100,000, divided into 20,000 common shares of a par value of 81 each and into 8,000 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at 232 St.James Street, West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-o Deputy Attorney General.(A.G.10349-55) Miss Susan Inc.Notice is hereby given that under Part.I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1955, incorporating: Frank F.Hubscher, advocate, Donald Kujan, student and Leona Green bookkeeper, spinster, of the full age of majority, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, under the name of \"Miss Susan Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided' into 100 common shares having a par value of $100 each and into 300 preferred shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 1007 (P.G.10379-55) M or id or Hosiery Limitée Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze février 1955, constituant en corporation: Roger Deslauriers, propriétaire et chauffeur de taxis, René Berteau, tricoteur, et Roland Guillet, notaire, tous d'Iberville, district judiciaire d'Iibervillc, pour les objets suivants: La fabrication et la vente, au gros et au détail, des bas façonnés et des produits connexes, sous le nom de \"Mondor Hosiery Limitée\", avec un capital total de §20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera au village de Mont-Saint-Grégoire, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur général, le quinze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(P.G.10319-55) National Door Ltd La Porte \"National\" Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre février 1955, constituant en corporation: J.-Éloi Gervais, Damase Brisscttc, avocats, \\\\e Longueuil, et Jacqueline Laliberté, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de la menuiserie, sous le nom de \"National Door Ltd \u2014 \u2014 La Porte \"National\" Ltée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 4,000 actions communes d'une valeur nominale de $10 chacune et en 600 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(P.G.10299-55) Notre Maison (Compagnie Limitée) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Petro Kinach, Iwan Zuban, constructeurs, et Petro Balahutrak, machiniste, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie foncière de construction et de développement, sous le nom de \"Notre Maison (Compagnie Limitée)\", avec un capital total de $100,000, divisé en 600 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(A.G.10379-55) Mondor Hosiery Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February 1955, incorporating: Roger Deslauriers, taxi owner and chauffeur, René Berteau, knitter, and Roland Guillet, notary, all of Iberville, judicial district of Iberville, for the following purposes: To manufacture and sell, wholesale and retail full fashioned hosiery and products connected therewith, under the name of \"Mondor Hosiery Limitée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of §100 each.The head office of the company will be at the village of Mont-Saint-Grégoire, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(A.G.10319-55) National Door Ltd La Porte \"National\" Ltce Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of February 1955, incorporating: J.-Éloi Gervais, Damase Brissette, advocates, of Longueuil, and Jacqueline Laliberté, secretary, fille majeure,-of Montréal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of, and deal in carpentry, under the name of \"National Door Ltd \u2014 La Porte \"National \" Ltée\", with a total capital stock of §100,000, divided into 4,000 common shares of a nominal value of $10 each and 600 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company will be at Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of February 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(A.G.10299-55) Notre Maison (Compagnie Limitée) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February^ 1955, incorporating: Petro Kinach, Iwan Zuban, builders, and Petro Balahutrak, machinist, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes : To carry on the operations of a real estate, building and development company, under the name of \"Nôtre-Maison (Compagnie Limitée)\", with a total capital stock of $100,000, divided into 600 common shares of à par value of $100 each, and into 400 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General. 1008 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 (P.G.10500-55) Octad Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-quatre février 1955, constituant en corporation: Ernest William Mockridgc, gérant, Alexander Gordon Yeoman, William Patrick Creagh, John Lawrence McCrory, Cecil Bruce Cooke, commis en loi, Clifford George Meek, Charles Eric Humphrey et Guy Ambrose Miller, teneurs de livres, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter, gérer et diriger des restaurants, sous le nom de \"Octad Limited\", avec un capital total de S20,000, divisé en 20,000 actions d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera en la cité de Lachine, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(P.G.10321-55) Opera Fur Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorze février 1955, constituant en corporation: Zchnan Najman, fourreur, d'Outremont, Harry Levkovitch.fourreur, Bernard Diamond, avocat et Alan Golden, commis, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de fourrures, sous le nom de \"Opera Fur Inc.\", avec un capital total de S40.000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 10 ouest rue Ontario, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(A.G.10500-55) Octad Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of February, 1955 incorporating: Ernest William Mockridge, manager, Alexnander Gordon Yeoman, William Patrick Creagh, John Lawrence McGrory, Cecil Bruce Cooke, law clerks, Clifford George Meek, Charles Eric Humphrey and Guy Ambrose Miller, bookkeepers, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate, manage and conduct restaurants, under the name of \"Octad Limited\", with a total capital stock of $20,000.divided into 20,000 shares of the par value of 81 each.The head office of the company will be at the city of Lachine, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General.(A.G.10321-55) Opera Fur Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1955, incorporating: Zclman Najman, furrier, of Outremont, Harry Levko, vitch, furrier, Bernard Diamond, advocate, and Alan Golden, clerk, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in furs, under the name of \"Opera Fur Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 10 Ontario Street, West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General.(P.G.10368-55) Parallel Construction Ltce Parallel Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze février 1955, constituant en corporation: Georges-Henri Brunet, comptable public, Raymond Boivin, commis de bureau, et Guy Valade, constructeur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeur et entrepreneur général, sous le nom de \"Parallel Construction Ltée \u2014 Parallel Construction Ltd.\", avec un capital total de S30.000, divisé en 300 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(A.G.10368-55) Parallel Construction Ltée Parallel Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February 1955, incorpc .ting: Georges Henri Brunet, public accountant, Raymond Boivin, office clerk, and Guy Valade, builder, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a builder and general contractor under the name of \"Parallel Construction Ltée \u2014 Parallel Construction Ltd.\", with a total capital stock of 830,000, divided into 300 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 1009 (P.G.10363-55) Peerless Paper Box Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorzième jour de février 1955, constituant en corporation: Frank F.Hubsclier, avocat, Lco-na Green, teneuse de livres, fille majeure, Donald Kujan, étudiant et Michael M.Ettinger, gérant de bureau, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de contenants, caisses et boîtes, sous le nom de \"Peerless Paper Box Co.\", avec un capital total de $80,-000, divisé en 600 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 7,400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatorzième jour de février 1955.L'Assistant-procu reu r général, 39475 C.E.CANTIN.(A.G.10363-55) Peerless Paper Box Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1955, incorporating: Frank F.Hubscher, advocate, Lcona Green, bookkeeper, spinster, of the full age of majority, Donald Kujan, student, and Michael M.Ettinger, office manager, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in containers, crates and boxes, under the name of \"Peerless Paper Box Co.\", with a total capital stock of $80,000, divided into 600 common shares having a par value of $10 each and into 7.400 preferred shares having a par value of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General.(P.G.10179-55) Perry Bcdbrook Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinzième jour de février 1955, constituant en corporation: Edward P.Bcdbrook, entrepreneur, Frances M.Bcdbrook, secrétaire, épouse séparée de biens dudit Edward P.Bcdbrook, tous deux de Beaurepaire et Robert A.Bcdbrook, architecte, de Dorval, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme entrepreneurs, constructeurs, couvreurs, sous le nom de \"Perry Bcdbrook Inc.\", avec un capital total de S40.000, divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Beau-repaire, dans la ville de Beaconsficld, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quinzième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(P.G.10389-55) Princess Fashion Shops Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinzième jour de février 1955, constituant en corporation: John L.Liberman, Moe Mosco-vitch, tous deux avocats et Mary Goldwatcr, secrétaire, épouse séparée de biens de son mari Sydney L.Goldwatcr, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de tailleurs, sous le nom ï»de \"Princess Fashion Shops Inc.\", avccuncapital total de 820,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quinzième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN., (A.G.10179-55) Perry Bcdbrook Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February, 1955, incorporating: Edward P.Bcdbrook, contractor, Frances M.Bcdbrook, secretary, wife separate as to property of the said Edward P.Bcdbrook, both of Beaurepaire, and Robert A.Bcdbrook, architect, of Dorval, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as contractors, builders, roofers, under the name of \"Perry Bcdbrook Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Beaurepaire in the town of Beaconsficld, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-o Deputy Attorney General.(A.G.10389-55) Princess Fashion Shops Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February, 1955, incorporating: John L.Liberman, Moe Moscovitch, both advocates, and Mary Goldwatcr, secretary, wife separate as to property form her husband Sydney L.Goldwatcr, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of tailors, under the name of \"Princess Fashion Shops Inc.\", with a total capital stock of 1820,000, divided into 100 common shares of the par value of $100 each and into 100 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General. 1010 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 (P.G.10370-\"55) Rapides Hardware Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date (lu quinze février 1955, constituant en corporation: Hyman Baker, Harold Newman, et William I.Miller, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de quincaillerie et accessoires, sous le nom de \"Rapides Hardware Ltd.\", avec un capital total de $40,-000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Laval-des-Rapides, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(P.G.10390-55) Rexley's Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinzième jour de février 1955, constituant en corporation: Irving Harry Reisler, marchand, de Ville St-Laurent, Sureka Wasserman, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous deux du district judiciaire de Montréal et Jacqueline Roberge, sténographe fille majeure, de Rosemère, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'un magasin de détail et aussi vendre en gros toutes sortes d'articles vestimentaires pour dames et messieurs, lingerie et vêtements de sport, sous le nom de \"Rexley's Ltd.\", avec un capital total do $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quinzième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(A.G.10370-55) Rapides Hardware Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February, 1955, incorporating: Hyman Baker, Harold Newman and William I.Miller, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in hardware and supplies, under the name of \"Rapides Hardware Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Laval-des-Rapides, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-o Deputy Attorney General.(A.G.10390-55) Rexley's Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February, 1955, incorporating: Irving Harry Reisler, merchant, of Ville St.Laurent, Sureka Wasserman, secretary, fille majeure, of Montreal, both of the judicial district of Montreal, and Jacqueline Roberge, stenographer, fille majeure, of Rosemère, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To carry on the business of a retail store and also to sell wholesale all types, of ladies' and men's apparel, lingerie and sportswear, under the name of \"Rexley's Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General.(P.G.10190-55) R.Théberge Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, eh date du trente et un janvier 1955, constituant en corporation: Robutel Théberge, chef de gare, Ivan Théberge, employé de bureau, Lucette Théberge, secrétaire, célibataire, et Gaétan Théberge, comtable agréé, tous de Thétford-Mines, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants : Exercer les entreprises de courtage en douanes, dédouanement de marchandises, sous le nom de \"R.Théberge Inc.\", avec un capital total de $4,000, divisé en 80 actions de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Thet-ford-Mines, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un janvier 1955.L'Assistant-procuteur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(A.G.10190-55) R.Théberge Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the [thirty-first day of January, 1955, incorporating: Robutel Théberge, station agent, Ivan Théberge, office employee, Lucette Théberge, secretary, spinster, and Gaétan Théberge, chartered accountant, all of Thetford-Mines, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To carry out the undertakings of custom\" brokers and the clearing of goods, under the name of \"R.Théberge Inc.\", with a total capital of $4,000, divided into 80 shares of $50 each.The head office of the company will be at Thetford-Mines, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of January, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 1011 (P.G.10231-55) R.Turcotte & Cie Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze février 1955, constituant en corporation: Arthur Boivin, avocat, de ville Mont-Royal, Rollande Boivin, secrétaire, de Montréal, tous deux du district judiciaire de Montréal, et J.J.Hamel, avocat, de Terrebonne, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de verrerie, sous le nom de \"R.Turcotte & Cie Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 15, rue Bernard, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(P.G.10305-55) Saguenay Premix Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre février 1955, constituant en corporation: Jules Landry, avocat, d'Arvida, Bernard L.Clermont, avocat, Bernadette Boulianne et Micheline Pedneault, secrétaires, ces trois derniers de Chicoutimi, tous du district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Saguenay Premix Inc.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Arvi-da, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le quatre février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(A.G.10231-55) R.Turcotte & Cie Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1955, incorporating: Arthur Boivin, advocate, of the town of Mount-Royal, Rollande Boivin, secretary, of Montreal, both of the judicial district of Montreal, and J.J.Hamel, advocate, of Terrebonne, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To carry on the business of and deal in glassware, under the name of \"R.Turcotte & Cie Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company shall be at 15, Bernard Street-East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(A.G.10305-55) Saguenay Premix Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the February fourth, 1955, incorporating: Jules Landry, advocate, of Arvida, Bernard L.Clermont, advocate, Bernadette Boulianne and Micheline Pedneault, secretaries, the latter three from Chicoutimi, all of the judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on the business of and deal in building materials under the name of \"Saguenay Premix Inc.\", with a capital total stock of $60,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Arvida, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.(P.G.10261-55) Tele Rediffusion Victoria Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze février 1955, constituant en corporation: Jean Roy, comptable agréé, Armand Saint-Pierre, arpenteur-géomètre, et Laurent Trottier, avocat, tous de Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants : Ériger dans le comté d'Arthabaska, une tour pour capter les ondes, sous le nom de \"Tele Rediffusion Victoria Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 1,500 actions communes de $10 chacune et en 350 actions privilégiées de.$100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le onze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.(A.G.10261-55) Tele Rediffusion Victoria Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of-Quebec, bearing date the eleventh day of February, 1955, incorporating: Jean Roy, chartered accountant, Armand Saint-Pierre, surveyor, and Laurent Trottier, advocate, all of Victoriaville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To erect in the county of Arthabaska, a receiving antenna tower under the name of \"Tele Rediffusion Victoria Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 1,500 common shares of $10 each and into 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Victoriaville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General. 1012 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 (P.G.10362-55) The Granville Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorze février 1955, constituant en corporation: Sydney Phillips, avocat, Tessy Frankel, secrétaire, célibataire, tous deux de Montréal et Norman Genser, avocat, de la ville de Hampstead, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme agents, sous-agents ou courtiers pour la transaction d'affaires d'assurance, sous le nom de \"The Granville Corp.\", avec un capital total de S20.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 190 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(A.G.10362-55) The Granville Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1955, incorporating: Sydney Phillips, advocate, Tessy Frankel, secretary, unmarried, both of Montreal, and Norman Genser, advocate, of the town of Hampstead, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as agent, sub-agent or broker to transact the business of insurance, under the name of \"The Granville Corp.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares having a par value of $1 each and into 190 preferred shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney .General, this fourteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General.(P.G.10398-55) The Paradise Ltd Avis est -donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seize février 1955, constituant en corporation: Edwin McKenzie, Eustache Moore, tous deux marchands et Duncan E.W.Rapier, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et administrer des terrains et bâtisses, sous le nom de \"The Paradise Ltd\", avec un capital total de $20,000, divisée en 200 actions de $100 chacune.Le siège 'social de la compagnie sera à 1252 ouest, rue St-Antoinc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(P.G.10327-55) Town & Country Cleaners Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorzième jour de février 1955, constituant en corporation: John J.Wasserman, avocat, de Westmount, Sydney Phillips, avocat et Tessy Frankel, sténographe, fille majeure, tous deux de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de nettoyeurs, presseurs, teinturiers, tailleurs, fourreurs, dresseurs (de chapeaux), réparateurs et donner un service général pour tous articles et tissus, sous le nom de \"Town & Country Cleaners Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatorzième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(A.G.10398-55) The Paradise Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenafht-Govcrnor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of February, 1955, incorporating: Edwin McKenzie, Eustache Moore, both Merchants, and Duncan E.W.Rapier, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and manage lands and buildings, under the name of \"The Paradise Ltd\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1252 St.Antoine Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General.(A.G.10327-55) Town & Country Cleaners Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1955, incorporating: John J.Wasserman, advocate, of Westmount, Sydney Phillips, advocate, and Tessy Frankel, stenographer, spinster of the full age of majority, both of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on generally the business of cleaners, pressors, dyers, tailors, furriers, blockers, repairers and general service of all articles and materials, under the name of \"Town & Country Cleaners Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39475-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1966, Vol.87, No.IS 1013 (P.G.10585-55) Westmount Sales Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois mars 1955, constituant en corporation: François Xavier Antoine Biron, avocat, Alcide Grenon, comptable, tous deux de Montréal et Pierrette Laplante, secrétaire, fille majeure, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Négocier et faire le commerce d'appareils de télévision et de radio, appareils et accessoires électriques et dispositifs d'utilité domestique et commerciaux, sous le nom de \"Westmount Sales Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 150 actions ordinaires de 8100 chacune et 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois mars 1955.L'Assistant-procureur général, 39475 C.E.CANTIN.(P.G.10373-55) Wilfrid Giroux Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze février 1955, constituant en corporation: Wilfrid Giroux, marchand, Leopold Francœur et André Trottier, ces deux derniers comptables agréés, tous de Sherbrooke, 'district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Faire affaires comme épicier-boucher, sous le nom de* \"Wilfrid Giroux Limitée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions d'une valeur au pair de $40 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le onze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39475-0 C.E.CANTIN.Maison Saint-Joseph Avis est donné qu'eu vertu des dispositions de l'article 20 de la Loi des évoques catholiques romains, 14 George VI, chapitre 76, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize mars 1955, constituant en corporation la \"Maison Saint-Joseph\".Le siège social de la corporation ci-haut mentionnée est situé en la ville de Jonquière, comté de Chicoutimi.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-trois mars 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39518-0 JEAN BRUCHÉSI.(A.G.10585-55) Westmount Sales Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of March, 1955, incorporating: FYançois Xavier Antoine Biron, advocate, Alcide Grcnon, accountant, both of Montreal, and Pierrette Laplante, secretary, spinster of age, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To trade and deal in television and radio sets, electric appliances and accessories ard domestic and commercial appliances, under the name of \"Westmount Sales Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 150 common shares of $100 each and into 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of March, 1955.C.E.CANTIN, 39475-o Deputy Attorney General.(A.G.10373-55) Wilfrid Giroux Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of February 1955, incorporating: Wilfrid Giroux, merchant, Leopold Francœur, and André Trottier, the two latter, chartered accountants, all of Sherbrooke, judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To carry on business as grocers and butchers, under the name of \"Wilfrid Giroux Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 shares of a par value of $40 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint FYancis.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of February 1955.C.E.CANTIN, 39475 Deputy Attorney General.Maison Saint-Joseph Notice is hereby given that under provisions of section 20 of the Roman Catholic Bishops Act, 14 George VI, chapter 76, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec dated March sixteenth, 1955, incorporating: \"Maison Saint-Joseph\".The head office of the corporation above mentioned is situate in the town of Jonquiere, county of Chicoutimi.Given at the office of the Provincial Secretary, on March twenty-three, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39518 Under Secretary of the Province.Actions en séparation de biens Province de Québec, district de Rimouski, Cour Supérieure, N° 15710.Dame Fernande St.Jean, ménagère, et épouse commune en biens de C.-E.Chamberland domiciliée à Mont-Joly, district de Rimouski, Province de Québec, demanderesse, vs C.-E.Chamberland, domicilié Actions for Separation as to Property Province of Quebec, district of Rimouski, Superior Court, No.15710.Dame F'ernande St.Jean, housekeeper and wife of C.-E.Chamberland, domiciled at Mont-Joly, district of Rimouski, Province of Quebec, plaintiff, vs C.-E.Chamberland, domiciled at Mont-Joly, 1014 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 à'Mont-Joly, district de Rimouski, Province de Québec, défendeur.Avis d'action en séparation de biens Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 4 janvier 1955.Montréal, 17 mars 1955.Le Procureur de la demanderesse, 39486-0 YVON PERRAS.Canada,, Province de Québec, district de St-François, Cour Supérieure, N° 13488.Dame Laurette Roy, épouse commune en biens de Yvon Boutin, journalier, du comté de Stanstead, district de St-François, demanderesse, vs ledit Yvon Boutin, des mêmes lieux, défendeur.Avis d'action en séparation de biens Une action en séparation de biens a été insti-\u2022 tuée en cette cause le 17 mars 1955 à Sherbrooke.Sherbrooke, le 17 mars 1955.Les Procureurs de la demanderesse, 39476-0 DENIS & DENIS.Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 370,386.Dame Marie-Anne Lagacé, des cité et district de Montréal, épouse commune en biens de Eliodore Lord, garagiste, des mêmes lieux, demanderesse, vs Eliodore Lord, des cité et district de Montréal, défendeur.Avis d'action en séparation de biens Une action en séparation de biens a été instituée, en cette cause, par la demanderesse contre le défendeur.Montréal, 18 mars 1955.L'Avocat de la demanderesse, 39492-0 GEO.-E.LOISELLE.district of Rimouski, Province of Quebec, defendant.Notice of separation as to propertv An action for separation as to property has been instituted in this case on January 4th, 1955.Montreal, March 17th 1955.YVON PERRAS, 39486-o Attorney for the plaintiff.Canada, Province of Quebec, district of St-Francis, Superior Court, No.13488.Dame Laurette Roy, wife common as to property of Yvon Boutin, laborer, of county of Stanstead, district of St-Francis, plaintiff, vs Yvon Boutin, of the same place, defendant.Notice op separation as to property An action in separation as to property has been instituted in this case on March the 17th, 1955, at Sherbrooke.Sherbrooke, the 17th of March 1955.DENIS & DENIS, 39476-0 Attorneys for the plaintiff.Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.370,386.Dame Marie-Anne Lagacé, of the city and district of Montreal, wife common as to property of Eliodore Lord, garage owner, of the same place, plaintiff, vs Eliodore Lord, of the city and district of Montreal, defendant.?Notice of separation as to property An action in separation as to property has been instituted by the plaintiff, against the defendant.Montreal, March 18th, 1955.GEO.-E.LOISELLE, 39492-0 Attorney for the plaintiff.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 279 Québec, le 17 mars 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"C\" Concernant la prolongation du droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Montréal.Il est ordonné, sur la proposition de l'hono-ragle Ministre du Travail: Que le droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Montréal, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 627-G du 17 juin 1954, soit prolongé jusqu'au 1er juillet 1955 aux mêmes taux et conditions.L.DÉSILETS, 39490-o Greffier du Conseil Exécutif.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 279 Quebec, March 17th, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"C\" Concerning an extension of the right to levy of the Building Trades and Joint Committee of Montreal.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour.That the right to levy of the Building Trades Joint Committee of Montreal, authorized by a by-law approved by Order in Council number 627-G of June 17th, 1954, be extended until July 1st, 1955, with the same rate and conditions.L.DÉSILETS, 39490-o Clerk of the Executive Council. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 1015 ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 279 Québec, le 17 mars 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"D\" Concernant la prolongation du droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Montréal re: administration du décret relatif à l'industrie du fer structural dans la province.II.est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Montréal, relativement à l'administration du décret numéro 862 du 23 juillet 1953, relatif à l'industrie du fer structural dans la province, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 355-B du 7 avril 1954, soit prolongé jusqu'au 1er juillet 1955 aux mêmes taux et conditions.(Document \"D\" annexé à l'arrêté) L.DÉSILETS, 39490-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 280 Québec, le 17 mars 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"A\" Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux installations électriques, rendue obligatoire par la section \"E\" du décret numéro 1021 du 10 septembre 1953, amendé par les arrêtés en conseil numéros 1257-C et 1378-A des 11 novembre et 23 décembre 1953, 192-A, 191-G, 851-A et 894-C des 11 mars, 21 août et 2 septembre 1954, et 21 du 5 janvier 1955, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal, ont présenté au Ministre du Travail, une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil, certaines modifications à ladite section \"E\" (article XXV) dudit décret: Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 29 janvier 1955; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail, Que l'article XXV dudit décret, numéro 1021, soit modifié comme suit: 1° Le paragraphe \"6\" dudit article est remplacé par le suivant: \"6) Taux minima de salaires: Les taux minima de salaires sont les suivants: ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 279 Quebec, March 17th, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"D\" Concerning an extension of the right to levy of the Building Trades Joint Committee of Montreal Re: administration of the decree relating to the structural iron industry in the Province.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the right to levy of the Building Trades Joint Committee of Montreal respecting the administration of the decree No.862 of July 23rd, 1953, relating to the structural iron industry in the Province, authorized by a by-law approved by Order in Council No.355-B of April 7th, 1954, be extended until July 1st, 1955, with the same rate and conditions.(Document \"D\" annexed to the order) L.DÉSILETS, 39490-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 280 Quebec, March 17th, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council., Part \"A\" Concerning amendments of the decree relating to the construction industry and trades in the region of Montreal.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the electrical installations, rendered obligatory by Part \"E\" of the decree No.1021 of September 10th, 1953, amended by Orders in Council Nos.1257-C and 1378-A of November 11th and December 23rd, 1953, 192-A, 191-G, 851-A and 894-C of March 11th, August 21st and September 2nd, J954, and 21 of January 5th, 1955, relating to the construction industry and trades in the region of Montreal, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the said part \"E\" (Section XXV) of the said decree; v Whereas the petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of January 29th, 1955; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That section XXV of the said decree.No.1021, be amended as follows: 1.Subsection \"6\" of the said section is replaced by the following: \"b) Schedule of wage rates: The following mini-mim wage rates shall be payable: 1016 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 L'heure Entrepreneur maître-électricien travaillant comme salarié et détenteur de la licence \"A\", qu'il utilise ses outils ou agisse comme contremaître ou remplisse tout autre fonction de surveillance.82.75 Le détenteur de la licence \"B\", qu'il utilise ses outils ou agisse comme contremaître ou remplisse toute autre fonction de surveillance.2.75 Compagnon électricien, détenteur de la licence \"C\".2.00 Apprentis: Les taux de salaires payables aux apprentis sont fixés suivant le pourcentage du salaire minimum légal payé au compagnon-électricien; ce pourcentage de rémunération est le suivant: 1ère année.40% 2ème année.50% Sème année.60% 4ème année.75% Tout électricien ou contremaître ayant 5 compagnons-électriciens et 5 apprentis ou plus, sous sa direction, lorsqu'il s'agit de travaux de construction ou de modernisation, doit bénéficier d'une majoration de 80.25 pour chaque heure de travail.\" 2° Le paragraphe \"d\" est abrogé et remplacé par le suivant: \"d) Travail supplémentaire: 1.Tout travail exécuté en plus des heures régulières ou en dehors des limites horaires déterminées au paragraphe précédent, est considéré comme du travail supplémentaire.2.Tout travail supplémentaire, à l'exclusion des dispositions prévues aux sous-paragraphes suivants, doit être rémunéré au taux de salaire et demi par rapport au taux de salaire minimum établi dans le présent article ou par rapport au taux de salaire effectivement payé, lorsque ce dernier est plus élevé.3.Tout travail exécuté entre 10.00 p.m.et 8.00 a.m., les lundi, mardi, mercredi jeudi et vendredi et après 1.00 p.m.le samedi, doit être rémunéré au taux de salaire double par rapport au taux de salaire minimum établi dans le présent article ou par - rapport au taux de salaire effectivement payé lorsque ce dernier est plus élevé.4.Aucun employeur n'a le droit de punir ou de menacer de punir, tel que par congédiement ou suspension, directement ou indirectement, un ouvrier qui s'absente du chantier un jour de de fête religieuse de sa foi.5.Equipes irrégulières: Un supplément de $0.10 l'heure doit être versé aux salariés appelés à exécuter leur travail quotidien en deux étapes séparées par plus d'une heure (broken shift).Par dérogation aux taux édictés pour les heures supplémentaires aux alinéas précédents, les cinq premières heures du temps supplémentaires doivent être rémunérées au taux de salaire et demi, les heures suivantes au taux de salaire double, basé sur le taux régulier ou sur le salaire effectivement payé lorsque ce dernier est plus élevé.6.Tout travail urgent d'altération ou de réparation à un immeuble qui, pour des raisons suffisantes, ne peut être exécuté en deçà des limites horaires déterminées ci-haut pour le commencement et la cessation du travail, peut être fait en d'autres périodes de la journée, aux taux réguliers.Toutefois, ledit travail supplémentaire demeure toujours sujet à la limite de huit (8) heures par jour et de quarante (40) heures par semaine.Tous les salariés affectés à un tel travail doivent recevoir un supplément de $0.05 sur les taux réguliers.\" per hour Contracting Master Electrician working as an employee and holding licence \"A\", whether be uses his tools or acts as foreman or fulfils any other supervisory functions.$2.75 Holder of license \"B\", whether he uses his tools or acts as foreman or fulfils any other supervisory functions.,.2.75 Electrician journeyman holding licence \"C\".2.00 Apprentice: Rates of wages paid to apprentices shall be fixed according to the following percentage of legal minimum wages paid to the electrician journeymen: , 1st year.40% 2nd year.50% 3rd vcar.60% 4th year.75% Every electrician or foreman in charge of five electrician journeymen and five apprentices or more shall be entitled to a surplus of $0.25 per hour for each working hours for construction or modernization work.\" 2.Subsection \"d\" is deleted and the following substituted therefor: \"d) Overtime: 1.All time worked in excess of the regular hours or beyond the hours mentioned in the foregoing subsection is considered as overtime.2.All overtime, except for the provisions of the following paragraphs, shall be paid at the rate of time and one half based on the minimum wage rate established in the present section, or on the wage rate actually paid if the latter be higher.3.All time worked between 10.00 p.m.and 8.00 a.m.on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, and after 1.00 p.m.on Saturday, shall be paid at the rate of double time based on the minimum wage rate established in the present section, or on the wage rate actually paid if the latter be higher.4.No employer has the right to punish, or to threaten to punish, by discharge or suspension, directly or indirectly, a worker who absents himself from work on a religious holiday of his faith.5.Broken shifts: A premium of SO.10 per hour shall be paid to employees working on any day shift broken by more than one hour.Notwithstanding the rates established for overtime in the foregoing paragraphs, the first five hours of overtime shall be paid at the rate of time and one half and the following hours at the rate of double time based on the regular rate, or on the rate actually paid if the latter be higher.6.All urgent building alteration or repair work which, for sufficient reasons, cannot be done within the limits of hours hercabove determined for starting and finishing, may be done in other periods of the day, at regular rates.However, such overtime work is always subject to the 8-hour daily limit and the 40-hour weekly limit.All employees engaged in such work shall receive a premium of S0.05 over the regular rates.\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 20th, 1955, Vol.87, No.12 1017 3° Le deuxième alinéa du paragraphe \"e\" est remplacé par le suivant: \"Les salariés travaillant en dehors des limites de la cité, doivent se rendre sur le chantier et le quitter aux heures régulières.Le temps requis pour se rendre des limites de la ville au chantier et pour revenir aux limites, doit leur être payé au taux simple ainsi que le prix du transport pour ledit trajet.\" 4° Le dernier alinéa du paragraphe \"e\" est remplacé par le suivant: \"Les frais de pension et de transport doivent être payés par l'employeur lorsqu'il s'agit de travaux exécutés en dehors des limites de Montréal.\" (Document \"A\" annexé à l'arrêté).L.DÉSILETS, 39490-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 280 Québec, le 17 mars 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"B\" Concernant des modifications au décret relatif à la métallurgie dans la région de Québec.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts rc-jondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de la métallurgie dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 973 du 24 juin 1948, amendé par les arrêtés en conseil numéros 1390-C du 21 octobre 1948, 883-A et 1197-B des 11 août et 27 octobre 1949, 1094-A du 4 octobre 1950, 93-D et 894-D des 25 janvier et 14 août 1951, 139-B et 503-B des 27 février et 7 mai 1952, 448-A, 860-B et 1157-D des 16 avril, 23 juillet et 23 octobre 1953, 7.75-C et 1151-F des 28 juillet et 18 novembre 1954, ont présenté au Ministre du.Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil, certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édjtion du 29 janvier 1955; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 973, soit modifié comme suit: 1° Le paragraphe \"c\" de l'article I est remplacé par le suivant: \"c) Le terme \"traceur en mécanique\" désigne tout salarié qui, d'après des plans et devis, indique sur les plaques de métal les modifications à apporter pour la fabrication des pièces mécaniques.Le terme \"traceur en structure\" désigne tout salarié qui, d'après des plans et devis, indique sur des plaques de métal les modifications à apporter pour la fabrication des pièces structurales ou autres pièces métalliques.\" 2° L'alinéa \"ii\" du sous-paragraphe 2 du paragraphe \"c\" de l'article II est remplacé par le suivant: \"ii.Les salariés travaillant dans les limites territoriales d'un chantier maritime où une con- 3.The second paragraph of subsection \"e\" is replaced by the following: \"Employees working outside the city limits shall get to and leave the job at the regular hours.The time required to go from the city limits to the job, and back to the limits, shall be paid straight time; the cost of such transportation shall also be paid by the employer.\" 4.The last paragraph of subsection \"e\" is replaced by the following: \"Board and travelling expenses shall be paid by the employer in the case of operations carried out outside the limits of Montreal.\" (Document \"A\" annexed to the order).L.DÉSILETS, 39490-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 280 Quebec, March 17th, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"B\" Concerning amendments to the decree relating to the metal trades in the region of Quebec.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the metal trades in the region of Quebec, rendered obligatory by the decree number 973 of June 24th, 1948, amended by Orders in Council number 1390-C of October 21st, 1948, 883-A and 1197-B of August 11th and October 27th, 1949, 1094-A of October 4th, 1950, 93-D and 894-D of January 25th and August 14th, 1951, 139-B and 503-B of February 27th and May 7th, 1952, 448-A, 860-B and 1157-D of April 16th, July 23rd, and October 23rd, 1953, 775-C and 1151-F of July 28th, and November 18th, 1954, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council certain amendments to the said decree; Whereas the petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of January 29th, 1955; Whereas no objection has been raised against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour: That the said decree, number 973, be amended as follows: 1.Subsection \"c\" of section I is replaced by the following: \"c) The term \"mechanical tracer\" means an employee who marks metal plates for the fabrication of mechanical parts, according to plans and specifications.The term \"structural tracer\" means an employee who marks metal plates for the fabrication of structural or other metal parts, according to plans and specifications.\" 2.Paragraph \"ii\" of paragraph 2 of subsection \"c\" of section II is replaced by the following: \"ii.Employees working within the limits of a shipyard where a private collective agreement 1018 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 mars 1955, Tome 87, JV° 12 vention collective particulière assure aux-dits salaires des conditions de travail et de salaire supérieures à celles du décret.Toutefois, même dans le cas d'un chantier maritime ayant une convention collective particulière assurant à.ses salariés des conditions de salaire et de travail supérieures à celles du décret, il est entendu que les salariés exerçant durant vingt-quatre (24) heures ou plus dans une semaine normale de travail les métiers prévus au paragraphe \"c\" du présent article, sont, automatiquement assujettis au décret, si ce chantier maritime effectue du travail autre que la construction ou la réparation maritime.\" 3° La classification \"Traceur.81.43 $1.32\" mentionnée dans l'échelle de salaire apparaissant au paragraphe \"a\" de l'article IV, est remplacée par les deux classifications suivantes: \"Traceur en mécanique.81.43 81.32 Traceur en structure.1.23 1.12\" 4° L'alinéa iv du paragraphe \"a\" de l'article V est remplacé par les suivants: \"iv) Dans les établissements de haute production en série, la journée de travail peut être de neuf heures et demie (9J^) rémunérées à temps simple, à la condition que la semaine de travail soit de cinq (5) jours, du lundi au vendredi inclusivement.\" \"v) Tout établissement doit chômer et payer au taux régulier à ses salariés deux (2) fêtes parmi les suivantes: la Toussaint, l'Immaculée-Conception, l'Epiphanie, le Vendredi-Saint, l'Ascension, la St-Jean-Baptiste, la fête de la Confédération (1er juillet), la fête du Travail.Toutefois les salariés ont droit à ces fêtes chômées et payées à la condition d'avoir été au travail la journée ouvrable qui précède le congé payé et la journée ouvrable qui le suit.\" \"vi) Dans les établissements ayant des équipes travaillant sur trois \"quarts\", les heures de travail s'établissent comme suit: 12.00 a.m.à 8.00 a.m.; 8.00 a.m.à 4.00 p.m.et 4.00 p.m.à 12.00 a.m.Nonobstant les autres stipulations du décret, le temps supplémentaire dans le cas de ces équipes est payé: 1.à temps et demi pour les trois prochaines heures en dehors des heures régulières de l'équi- **> 2.à temps double au-delà des trois heures ci-haut mentionnées.Tout salarié faisant partie de l'équipe de 4.00 p.m.à 12.00 a.m.a droit à 80.03 de plus l'heure que son salaire régulier; tout salarié faisant partie de l'équipe de 12.00 a.m.à 8.00 a.m.a droit à 80.05 de plus l'heure que son salaire régulier.\" (Document \"B\"' annexé à l'arrêté) L.DÉSILETS, 39490-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 280 Québec, le 17 mars 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil Section \"C\" Concernant la prolongation du décret relatif a l'industrie et aux métiers de la construction dans le région de Montréal.stipulates better working conditions and higher wages than those of the present decree.However, even in the case of a shipyard having a private collective agreement that assures the employees of better conditions and wages .than those of the present decree, it is understood that employees working twenty-four (24) or more hours in a standard work week at the trades mentioned in subsection \"c\" of the present section are automatically governed by the decree when such shipyard engages in operations other than shipbuilding or repairing.\" 3.The following item \"Tracer.$1.43 $1.32\" appearing in the wage scale, subsection \"a\" of section IV, is replaced by the following two classifications: \"Mechanical tracer.$1.43 $1.32 Structural tracer.1.23 1.12\" 4.Paragraph iv of subsection \"a\" of section V is replaced by the following: \"iv) In establishment engaged in mass production, the work day may consist of nine and a half ((93-^) hours paid straight time, providing the work week does not comprise more than five (5) days, from Monday to Friday inclusive.\" \"v) Every establishment must close on two (2) of the following holidays and pay straight time to its employees: All Saints Day, Immaculate Conception Day, Epiphany Day, Good Friday, Ascension Day, St.John the Baptist Day, Confederation Day (July 1st), Labour Day.However, employees shall be entitled to such holidays with pay only on the condition that they have worked the working day preceding such holidays and the one following them.\" \"vi) In establishments operating on a three-shift system, the hours of work shall be as follows: 12.00 a.m.to 8.00 a.m.; 8.00 a.m.to 4.00 p.m.and 4.00 p.m.to 12.00 a.m.Notwithstanding the other provisions of the decree, overtime for such shifts is paid: 1.at the rate or time and one half for the first three hours in excess of the regular hours of the shift; 2.at the rate of double time for all time worked in excess of the three hours above mentioned.Employees of the 4.00 p.m.to 12.00 a.m.shift are entitled to a premium of $0.03 per hour over their regular rate; employees of the 12.00 a.m.to 8.00 a.m.shift are entitled to a premium of $0.05 over their regular rate.\" (Document \"B\" annexed to the order) L.DÉSILETS, 39490-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 280 Quebec, March 17th, 1955.Present: The Lieutenant Governor in Council Part \"C\" Concerning an extension of the decree relating to the construction industry and trades in the region of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 1019 Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail : Que le décret numéro 1021 du 10 septembre 1953 et amendements, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal, soit prolongé jusqu'au 1er juillet 1955.(Document \"C\" annexé à l'arrêté) L.DÉSILETS, 39490-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 280 Québec, le 17 mars 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil Section \"D\" Concernant la prolongation du décret relatif à l'industrie du fer structural dans la province de Québec.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le décret numéro 862 du 23 juillet 1953 et amendements, relatif à l'industrie du fer structural dans la province de Québec, soit prolongé jusqu'au 1er juillet 1955.(Document \"D\" annexé à l'arrêté) L.DÉSILETS, 39490-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 280 Québec, le 17 mars 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"E\" Concernant des modifications au décret relatif au commerce de détail dans la cité de Chicoutimi et un rayon de cinq (5) milles-de ses limites à l'exclusion de la cité d'Arvida.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative au commerce de détail dans la cité de Chicoutimi et un rayon de cinq (5) milles de ses limites à l'exclusion de la cité d'Arvida, rendue obligatoire par le décret numéro 996 du 2 octobre 1952, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 22 janvier 1955; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 996, soit modifié comme suit: 1° Le Syndicat des Employés de Magasins de Chicoutimi est accepté comme partie con- It is ordered, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour.That the decree No.1021 of September 10th, 1953, and amendments, relating to the construction industry and trades in the region of Montreal, be extended until July 1st, 1955.(Document \"C\" annexé à l'arrêté) L.DÉSILETS, 39490-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER .Number 280 Quebec, March 17th, 1955.Present: The Lieutenant Governor in Council Part \"D\" Concerning an extension of the decree relating to the structural iron industry in the province of Quebec.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the decree No.862 of July 23rd, 1953, and amendments, relating to the structur.J iron industry in the province of Quebec, be extended until July 1st, 1955.(Document \"D\" annexed to the order) L.DÉSILETS, 39490-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Numéro 280 \u2014 Quebec, March 17th, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"E\" Concerning amendments of the decree relating to the retail trade in the city of Chicoutimi and a radius of five (5) miles from its limits, with the exception of the city of Arvida.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the retail trade in the city of Chicoutimi and a radius of five (5) miles from its limits, with the exception of the city of Arvida, rendered obligatory by the decree No.996 of October 2nd, 1952, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the said decree; Whereas the petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of January 22nd, 1955; Whereas the objections set forth have been duly considered, as required by the Act; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, No.996, be amended as follows: 1.\"Le Syndicat des Employés de Magasins de Chicoutimi\" is accepted as contracting party 1020 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 tractante de deuxième part et remplace à ce titre les deux Syndicats dont les noms apparaissent actuellement dans le décret.2° L'alinéa suivant est ajouté à l'article II (Juridiction professionnelle) : \"Nonobstant les dispositions précédentes, les salariés travaillant à la vente des produits pharmaceutiques, drogues et cosmétiques dans les pharmacies ne sont pas assujettis au présent décret.\" 3° Le paragraphe \"b\" de l'article IV est remplacé par le suivant: \"b) La semaine régulière de travail est la suivante : 1.Dans les épiceries, boucheries, épiceries-boucheries, épiceries-licenciées, restaurant-épiceries: \u2022 Quarante-sept heures et demie (473^) pour les salariés du sexe féminin et cinquante heures et demie (503/0 pour les salariés du sexe masculin, réparties comme suit: Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, la veille de Noël et la veille du Premier de l'An: Personnel masculin: de 8.00 a.m.à 5.30 p.m.Personnel féminin: de 8.30 a.m.à 5.30 p.m.Les vendredi et veilles des autres fêtes chômées et les trois (3) jours ouvrables précédant la veille de Noël, c'est-à-dire trois (3) jours où le travail devrait normalement cesser à 5.30 p.m.; Personnel masculin: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.Personnel féminin: de 8.30 a.m.à 9.00 p.m.2.Dans les autres magasins de détail régis par le décret: Quarante-quatre heures et demie (443/0 Sour les salariés du sexe féminin'et quarante-sept eures et demie (473^) pour les salariés du sexe masculin, réparties comme suit: Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, la veille de Noël et la veille du Premier de l'An: Personnel masculin: de 8.30 a.m.à 5.30 p.m.Personnel féminin: de 9.00 a.m.à 5.30 p.m.Les vendredi et veilles des autres fêtes chômées et les trois (3) jours ouvrables précédant la veille de Noël, c'est-à-dire trois (3) jours où le travail devrait normalement cesser à 5.30 p.m.: Personnel masculin: 8.30 a.m.à 9.00 p.m.Personnel féminin: 9.00 a.m.à 9.00 p.m.\" 4° Au paragraphe \"i\" de l'article IV, les mots \"peuvent être prolongées jusqu'au 10 heures p.m.\" sont remplacés par les mots \"peuvent être prolongées jusqu'au 6 heures p.m.les quatre premiers jours de la semaine, et jusqu'à 10.00 p.m.\" 5° Le paragraphe \"6\" de l'article V est remplacé par le suivant: \"b) Le salaire des salariés soumis à la semaine de cinquante heures et demie (503/0, de quarante-sept heures et demie (47 3/0 ou de quarante-quatre heures et demie (443/0.ne doit en rien être affecté par les fêtes chômées.\" 6° Le paragraphe 'V' de l'article VII est remplacé par le suivant: \"Vil.Salaires minima: a) Les taux de salaires minima sont les suivants: Taux hebdomadaires Hommes Femmes Chef de département ou premier commis.$49.00 $34.00 Chef d'allée.38.00 30.00 Comptable.47.00 Étalagiste.47.00 Boucher.49.00 Note: Tous les commis-bouchers sont soumis à la même échelle de salaires que les commis.Commis: of the second part and replaces the two Syndicates whose names now appear in the decree.2.The following paragraph is added to section II (Professional jurisdiction): \"Notwithstanding the foregoing provisions, the employees working at the sale of drugs and cosmetics in drugstores are not governed by the present decree.\" 3.Subsection \"b\" of section IV is replaced by the following: \"b) The standard work week shall be as follows: 1.In groceries, butcher shops, grocer-butcher shops, licensed groceries, restaurant-groceries: Forty-seven hours and a half (473/0 for female employees and fifty hours and a half (503/0 for male employees, distributed as follows: On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday and on the eves of Christmas and New Year's Day: Male employees: 8.00 a.m.to 5.30 p.m.Female employees: 8.30 a.m.to 5.30 p.m.On Friday and the eves of the other observed holidays, and on the three (3) working days preceding Christmas Eve, i.e.three (3) days on which work would normally cease at 5.30 p.m.: Male employees: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.Female employees: 8.30 a.m.to 9.00 p.m.2.In the other retail stores governed by the decree: Forty-four hours and a half (443^) for female employees, and forty-seven hours and a half (473^) for female employees, distributed as follows: On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday and on the eves of Christmas and New Year's Day: Male employees: 8.30 a.m.to 5.30 p.m.Female employees: 9.00 a.m.to 5.30 p.m.On Friday and the eves of the other observed holidays, and on the three (3) working days preceding Christmas Eve, i.e.three (3) days on which work would normally cease at 5.30 p.m.: v Male employees: 8.30 a.m.to 9.00 p.m.Female employees: 9.00 a.m.to 9.00 p.m.\" 4.In subsection \"i\" of section IV, the words \"may be extended until 10.00 p.m.\" are replaced by the words \"may be extended until 6.00 p.m.on the first four days of the week, and until 10.00 p.m.\" 5.Subsection \"6\" of section V is replaced by the following: \"b) The wages of employees whose regular work week consists of forty-four and half (443^), fifty and a half (503^) or forty-seven and a half (473^) hours shall not be affected by holidays.\" 6.Subsection \"a\" of section VII is replaced by the following: \"VII.Minimum wages: a) The minimum rates of wages shall be as follows: Wee/cly rates Males Females Departmental manager or chief clerk.$49.00 $34.00 Floorwalker.38.00 30.00 Accountant.47.00 Window dresser.47.00 Butcher.49.00 Note: All butcher clerks shall be paid the clerks' rates.Clerks: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 1021 1er semestre.$18.00 817.00 2ème semestre.20.00 18.00 2ème année.23.00 20.00 3ème année.27.00 23.00 4ème année.30.00 25.00 5ème année.35.00 Tous les salariés du sexe féminin de cette catégorie ayant quatre (4) années d'expérience ou plus doivent être payés comme suit: 1/3 classe A.$32.00 1/3 classe B.29.00 1/3 classe C.27.00 Tous les salariés du sexe masculin de cette catégorie ayant cinq (5) années d'expérience ou plus doivent être payés comirrc suit: 1/3 classe A.$42.00 1/3 classe B.39.00 1/3 classe C.37.00 Teneurs de livres: même taux que les commis jusqu'à concurrence de cinq (5) années accomplies.Subséquemment.$42.00 $32.00 Caissier ou caissière: même taux que les commis.Salariés à commission: même échelle de base que l'échelle minimum des commis.Livreur, habituellement chargé de la livraison avec camion, automobile ou voiture à traction animale.$43.00 Aide-livreur de 21 ans et plus chargé habituellement de la livraison avec camion, automobile ou voiture à traction animale.35.00 Aide-livreur de moins de 21 ans, mêmes taux gradués que les commis.Livreur à bicyclette.$15.00 La bicyclette et ses accessoires doivent être fournis par l'employeur qui doit également pourvoir aux réparations.Livreur à bicyclette de plus de seize ans (16): même taux que les commis.Couturière: même taux que les commis.\" 7° L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe \"c\" de l'article VII: \"Toutefois, pour bénéficier de ces taux, tout salarié surnuméraire doit avoir travaillé l'équivalent de 26 semaines de trente heures (30) dans le cas des femmes, et de 26 semaines de quarante heures (40) dans le cas des hommes.Pendant ces 26 premières semaines d'emploi, le taux horaire est de $0.40\".8° Le paragraphe \"/\" de l'article VII est radié.9° Les mots \"plus boni de vie chère\" apparaissant au paragraphe \"6\" de l'article VIII, sont radiés.10° Le paragraphe \"c\" de l'article VIII est radié.11° L'article IX est radié.(Document \"E\" annexé à l'arrêté) L.DÉSILETS, 39490-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF 1st six months.$18.00 $17.00 2nd six months.20.00 18.00 2nd year.23.00 20.00 3rd year.27.00 23.00 4th year.30.00 25.00 5th year.35.00 All female employees of this category with four (4) or more years of experience shall be paid as follows: 1/3 class A .r.$32.00 1/3 class B.29.00 1/3 class C:.27.00 All male employees of this category with five (5) or more years of experience shall be paid as follows: 1/3 class A.$42.00 1/3 class B.39.00 1/3 class C.37.00 Book-keepers: Clerks' rates up to the fifth (5th) year, inclusive.Thereafter.$42.00 S32.00 Cashier: clerks' rates.Commission salesmen: same basic minimum scale as clerks.Delivery man habitually in charge of the delivery with truck, automobile or horse-drawn vehicle.$43.00 Delivery man's helper of 21 or older, doing the delivery with truck, automobile or horse-drawn vehicle.'.35.00 Delivery man's helper under 21, same-progressive rates as clerks.Delivery employee (with bicycle) $15.00 The bicycle and its accessories shall be supplied by the employer who shall also keep same in repair.Delivery employees (with bicycle) over 16 years of age: Clerk's rates.Seemstress: Clerks' rates.\" 7.The following paragraph is added to subsection \"cV of section VII: \"However, to be entitled to these rates, occasional employees must work the equivalent of 26 weeks of thirty (30) hours in the case of female employees, and 26 weeks of forty (40) hours in the case of male employees.During these first 26 weeks of employment, the hourly rates shall be $0.40.\" 8.Subsection \"/\" of section VII is deleted.9.The words \"plus the cost of living bonus\" mentioned in subsection \"b\" of section VIII, are deleted.10.Subsection \"c\" of section VIII is deleted.11.Section IX is deleted.(Document \"E\" annexed to the order) L.DÉSILETS, 39490-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Numéro 280 Number 280 Québec, le 17 mars 1955.Quebec, March 17th, 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil Present: The Lieutenant Governor in Council Section \"F\" Part \"F\" Concernant une modification au décret relatif Concerning an amendment of the decree re-à l'industrie de la boulangerie et de la pâtis- lating to the baking and pastry making in-serie dans la région des Trois-Rivières.dustry in the region of Trois-Rivières. 1022 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la boulangerie et de la pâtisserie dans la région des Trois-Rivières, rendue obligatoire par le décret numéro 421 du 29 avril 1954, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil, une modification audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 29 janvier 1955; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 421, soit modifié comme suit: L'article IV est remplacé par le suivant: \"IV.Salaires minima: Les salaires minima des salariés assujettis au décret ne doivent pas être inférieurs aux taux ci-dessous mentionnés: a) Boulangers, pâtissiers: ^ Compagnons: par semaine 1er boulanger.$50.00 1er pâtissier.50.00 2ème boulanger.45.50 2ème pâtissier.45.50 3ème boulanger et les compagnons suivants.42.00 3ème pâtissier et les compagnons suivants.42.00 Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the baking and pastry making industry in the region of Trois-Rivières, rendered obligatory by the decree No.421 of April 29th, 1954, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council an amendment to the said degree; Whereas the petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of January 29th, 1955; Whereas no objection has been raised against the approval of the proposed amendment; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, No.421, he amended as follows: Section IV is replaced by the following: \"IV.Minimum wages: The minimum wages of employees governed by the decree shall not be less than the rates hereunder mentioned: a) Bakers, pastry-cooks: Journeymen: per week 1st baker.$50.00 1st pastry cook.50.00 2nd baker.45.50 2nd pastry cook.45.50 3rd baker and the following journeymen.42.00 3rd pastry cook and the following jouney- men.42.00 Apprentis: Apprentices: 1ère année.24.00 1st year.24.00 2èmeannée.28.00 2nd year.28.00 3èmeannée.32.00 3rd year.32.00 b) Distributeurs: Vingt pour cent (20%) sur les ventes au détail et huit pour cent (8%) sur les ventes dans le gros.c) Le salaire de tout vendeur qui achète ses produits des industries ci-haut mentionnées pour les vendre à son propre compte, soit dans les magasins ou dans les maisons privées, ne doit jamais être inférieur à $27.00 par semaine, s'il ne fournit que son temps et, s'il fournit son temps et son véhicule de quelque nature que ce soit, il ne doit jamais être inférieur à $37.00 par semaine.Les boulangeries et les pâtisseries pratiquant cette méthode sont responsables des salaires de ces salariés.\" (Document \"F\" annexé à l'arrêté) L.DÉSILETS, 39490-o Greffier du Conseil Exécutif.b) Distributors: Twenty percent (20%) on all retail sales and eight per cent (8%) on wholesale transactions.c) The wages of a salesman buying his products from the industries hereabove mentioned for the purposes of selling same on his own account, in stores or private homes, shall never be less than $27.00 per week for his time only; should he give his time and supply his vehicle (any kind of vehicle), his wages shall not be less than $37.00 per week.Bakeries and pastry making establishment having enforced that system shall be responsible \"for the wages of such employees.\" (Document \"F\" annexed to the order) L.DÉSILETS, 39490-o Clerk of the\"Executive Council.Assemblée Meeting AVIS Avis est, par les présentes, donné que l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie \"Quebec Central Railway Company\" sera tenue aux bureaux de la compagnie \"Canadian Pacific Railway Company\", Montréal, Canada, mercredi, le 20e jour d'avril 1955, à onze heures du matin, pour l'élection de deux directeurs représentant les obligataires et, en général, pour la transaction de toute autre affaire.NOTICE Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Shareholders of Quebec Central Railway Company will be held at the Offices of the Canadian Pacific Railway Company, Montreal, Canada, on Wednesday, the 20th day of April, 1955, at the hour of eleven o'clock in the forenoon, for the election of- two Directors representing the Security Holders and, for the transaction of business generally. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 1023 Les actionnaires enregistrés le 16e jour de mars 1955 peuvent assister et voter à l'assemblée.Daté à Montréal, Canada, le 1er jour de mars 1955.Le Secrétaire, 39452-11-3 C.NIDEROST.Avis divers (Sec.P.163-53) AVIS (Loi des compagnies à fonds social étrangères) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu la copie d'une nouvelle procuration, en date du 8 décembre 1954, de la compagnie \"Gamlen Chemical Company\", corporation étrangère dûment autorisée à faire affaires en cette province.En vertu de ladite nouvelle procuration, M.Robert Gérard Sampson, avocat, a été nommé agent principal de la compagnie dans la province de Québec, et le principal bureau d'affaires de la compagnie est établi au bureau dudit agent principal: chambre 404, 31, rue Saint-Jacques, ouest, en les cité et district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le quinze mars 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39477-0 JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Rex Credit Union\", en date du 16 février 1955, dont le siège social est situé à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le vingt-huit février 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39478-0 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.12174-54) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le dix-sept mars 1955, les règlements numéro I et II de l'\"Hôpital Notre Dame du Sacré-Cœur\", tels qu'adoptés à l'assemblée tenue le 9 février 1955, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le dix-huit mars 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39491-0 JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la loi 11 George VI, chapitre 52, article 5, l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le dix-huit mars 1955, la fin de l'existence corporative de \"L'Association Canadienne des Employés de Tramways de Montréal\", dont la constitution en syndicat professionnel a Stockholders of record on the 16th day of March, 1955, may attend and vote.Dated at Montreal, Canada, this 1st day of March, 1955.C.NIDEROST, 39452-11 -3-o Secretary.Miscellaneous Notices (P.Sec.163-53) NOTICE (Extra-Provincial Companies' Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received copy of a new power of Attorney dated December 8th, 1954, from the company \"Gamlen Chemical Company\", extra-provincial corporation duly authorized to carry on business in this Province.Under the said new power the Attorney, Mr.Robert Gérard Sampson, lawyer, has been named principal agent for the company in the Province of Quebec, and the head office of the company is established at the office of the said principal agent: Room 404, 31, Saint-James, West, in the city and judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, on March fifteenth, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39477 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Rex Credit Union\", under date February 16th, 1955, whereof the head office is at Montreal, in the judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-eighth day of February, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39478 Under Secretary of the Province.(A.G.12174-54) Notice is given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary of the Province has approved, on the seventeenth day of March, 1955, by-laws number I and II of \"Hôpital Notre Dame du Sacré-Cœur\", as adopted at a meeting held February 9th, 1955, and such, pursuant to the provions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, the eighteenth day of March, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39491 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162, as added thereto by Act 11 George VI, chapter 52, section 5, the Honourable Provincial Secretary has enacted, on March eighteenth 1955, the termination of the corporate existence of \"L'Association Canadienne des Employés de Tramways de Montréal\", the constitution of which as a professional syn- 1024 GAZETTE OFFICIELLE BE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 21 été autorisée le vingt-trois avril 1946, avec son siège social à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le vingt et un mars 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39503-o JEAN BRUCHÉSI.Sommaire du Règlement N° 8 de Trican Petho-Chemical Cokporation (No Personal Liability) Par le règlement N° 8 de la compagnie \"Trican Petro-Chemical Corporation\" (No Personal Liability), Suite 5, 1551 rue Bishop, Montréal, Québec, passé par le bureau de direction le 11 février 1955 et ratifié, sanctionné et confirmé par les actionnaires par un vote de 100% des actionnaires présents ou représentés par procuration à une assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 18 mars 1955, la compagnie a été autorisée cà vendre ses propriétés, actifs et responsabilités à Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability), suite 420, 1410 rue Stanley, Montréal, Québec, pour 1,121,869 actions ordinaires entièrement acquittées et non répar-tissables de la compagnie Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability) et distribuer lesdites 1,121,869 actions de Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability) au pro rata entre les actionnaires de Trican Petro-Chemical Corporation (No Personal Liability) au taux d'une action de Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability) pour chaque trois actions de Trican Petro-Chemical Corporation (No Personal Liability) remises pour annulation à une date devant être fixée par résolution du bureau de direction et demander au Procureur général de la province de Québec l'acceptation de l'abandon de sa charte et une directive quant à son annulation et la fixation d'une date à compter de laquelle la compagnie sera dissoute.Le Secrétaire, 39516 MARCEL LAJEUNESSE.Sommaire du Règlement N° 13 de Tri-Tor Oils Ltd.(No Personal Liability) Par le règlement N° 13 de Tri-Tor Oils Ltd.(No Personal Liability), suite 420, 1410 rue Stanley, Montréal, Québec, passé par le bureau de direction le quatorzième jour de février 1955, et ratifié, sanctionné et confirmé par les actionnaires par un vote de 100% des actionnaires présents ou représentés par produration à une assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 1S mars 1955, la compagnie a été autorisée à vendre ses propriétés, actifs et responsabilités 4 Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability), suite 420, 1410 rue Stanley, Montréal, Québec, pour 1,539,558 actions ordinaires entièrement acquittées et non répartis-sablcs de la compagnie Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability) et distribuer lesdites 1,539,558 actions de Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability) au pro rate entre les actionnaires de Tri-Tor Oils Ltd.(No Personal Liability) au taux d'une action de Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability) pour chaque trois actions de Tri-Tor Oils Ltd.(No Personal Liability) remises pour annulation à une date devant être fixée par une résolution du bureau de direction et demander au Procureur général de la province de Québec l'acceptation de l'abandon de sa dicate had been authorized the twenty-third day of April 1946, with head office at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, the twenty-first day of March 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39503 Under Secretary of the Province.Summary of By-law No.8 of Trican Petro-Chemical Corporation (No Personal Liability) By By-law No.8 of \"Trican Petro-Chemical Corporation\" (No Personal Liability), Suite 5, 1551 Bishop Street, Montreal, Quebec, passed by the Board of Directors on the eleventh of February, 1955 and ratified, sanctioned and confirmed by the Shareholders by a vote of 100% of the shareholders present or represented by Proxy at a Special General Meeting of Shareholders held on March 18th, 1955, the Company was authorized to sell its properties, assets and liabilities to Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability), Suite 420, 1410 Stanley Street, Montreal, Quebec, for 1,121,869 fully-paid and non-assessable common shares of Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability), and to distribute the said 1,121,869 shares of Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability) rateably among the Shareholders of Trican Petro-Chemical Corporation (No Personal Liability) at the ratio of one share of Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability) for each three shares of Trican Petro-Chemical Corporation (No-Personal Liability) surrendered for cancellation on a date to be fixed by resolution of the Board of Directors and to apply to the Attorney General of the Province of Quebec for an order accepting the surrender of its charter and directing its cancellation and fixing a date upon and from which the Company shall be dissolved.MARCEL LAJEUNESSE, 39516-0 Secretary.Summary of By-law No.13 of Tri-Tor Oils Ltd.(No Personal Liability) By by-law No.13 of Tri-Tor Oils Ltd.(No Personal Liability), suite 420, 1410 Stanley Street, Montreal, Quebec, passed by the Board of Directors on the fourteenth day of February, 1955, and ratified, sanctioned and confirmed by the Shareholders by a vote of 100% of the Shareholders present or represented by Proxy at a Special General Meeting of Shareholders held on March 18lh, 1955, the Company was authorized to sell its properties, assets and liabilities to Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability), Suite 420, 1410 Stanley Street, Montreal, Quebec, for 1,539,558 fully-paid and non-assessable common shares of Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability), and to distribute the said 1,539,558 shares of Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability) rateably among the Shareholders of Tri-Tor Oils Ltd.(No Personal Liability) at the ratio of one share of Bonnyville Oil & Refining Corporation (No Personal Liability) for each three shares of Tri-Tor Oils Ltd.(No Personal Liability) surrendered for cancellation on a date to be fixed by resolution of the Board of Directors and to apply to the Attorney General of the Province of Quebec for an order accepting the surrender QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 1025 charte et une directive quant à son annulation et la fixation d'une date à compter de laquelle la compagnie sera dissoute.Le Secrétaire, 39517 MARCEL LA.TEUNESSE.(P.G.14891-52) K.R.T.Alumni Association, Incorporated Extrait du règlement N° 1 de la corporation nommée ci-dessus concernant une augmentation du nombre de ses directeurs de trois (3) à neuf (9): \"3.Bureau de direction \u2014 Les affaires de l'association seront administrées par un bureau de direction consistant, le nombre le permettant, en neuf (9) membres de l'association.\" Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 39519 R.DOUGLAS.(P.G.12224-54) Property Owners Association of Pincourt L'Association des Propriétaires de Pincourt Extrait des règlements de la corporation nommée ci-dessus concernant une augmentation du nombre de ses directeurs de neuf (9) à douze (12) : \"Article 8 \u2014 Bureau de direction \u2014 Le bureau de direction sera composé de: (1) Le Président, les Vices-Présidents, le Secrétaire, le Trésorier et deux autres directeurs faisant un total de douze directeurs élus à l'assemblée générale annuelle.Lorsque le bureau de direction se compose de douze directeurs, sept formeront un quorum légal.\" Certifié vraie copie, Montréal, 22 février 1955.Le Secrétaire, 39520 LAURENT VALADE.(PG.18180-53) St.Hubert Television Sales Co.Ltd.Bcglcmcnt N° 22 \"Que le nombre des directeurs de \"St.Hubert Television Sales Co.Ltd.\" soit augmenté de trois à quatre.\" Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 39521 L.GOLDSMITH: (P.G.11965-54) Two Mountains Masonic Corporation Extrait du règlement de la corporation nommée ci-dessus, tel qu'adopté le 12 novembre 1954, concernant une augmentation du nombre de ses directeurs de quatre (4) à dix (10): \"N° 4 \u2014 Bureau de direction \u2014 Les affaires de la corporation seront administrées par un bureau de direction composé de dix (10) membres de la corporation dont les services ne seront pas rémunérés et élus à l'assemblée annuelle de la corporation.\" Certifié vraie copie.of its charter and directing its cancellation and fixing a date upon and from which the Company shall be dissolved.MARCEL LAJEUNESSE, 39517-o Secretary.(A.G.14891-52) K.R.T.Alumni Association, Incorporated Extract of by-law No.1 of the above named corporation concerning an increase in the directorate thereof from three (3) to nine (9): \"3.Board of directors \u2014 The affairs of the association shall be managed by a board of directors consisting, as soon as numbers permit, of nine (9) members of the association.\" Certified true copy.R.DOUGLAS, 39519-o Secretary.(A.G.12224-54) Property Owners Association of Pincourt L'Association des Propriétaires de Pincourt Extract from the by-laws of the above named corporation concerning an increase in the directorate thereof from nine (9) to twelve (12) : \"Article 8 \u2014 Board of Directors \u2014 The Board of Directors shall consist of: (1) The President, the Vice-Presidents, the Secretary, the Treasurer and two other Directors, making a total of twelve Directors to be elected at the Annual General Meeting.When the Board of Directors consists of twelve Directors, seven shall constitute a legal quorum.\" Certified to be a true copy, Montreal, this 22nd February, 1955.LAURENT VALADE, 39520-o Secretary.(A.G.18180-53) St.Hubert Television Sales Co.Ltd.By-law No.22 \"That the number of Directors of \"St.Hubert Television Sales Co.Ltd.\" be increased from three to four.\" Certified to be true copy.L.GOLDSMITH, 39521-0 Secretary.(A.G.11965-54) Two Mountains Masonic Corporation Extract of the by-laws of the above named corporation, as adopted on November 12th, 1954, concerning an increase in the directorate thereof from four (4) to ten (10): \"No.4 \u2014'\u2022 Board of directors \u2014 The affairs of the Corporation shall be managed by a Board of Directors consisting of-ten (10) members of the Corporation whose services will not be remunerated, elected at the Annual Meeting of the Corporation.\" Certified a true copy.39522 Le Secrétaire, RONALD GLEESON.39522-0 RONALD GLEESON, Secretary. 1026 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 Charte \u2014 Abandon de AVIS Bureau d'Assistance Sociale aux Familles Avis est donné que le \"Bureau (l'Assistance Sociale aux Familles\", une corporation constituée en vertu de la Loi des Compagnies de Québec et ayant son siège social- dans la cité de Montréal, s'adressera au Procureur Général de la Province de Québec pour demander la permission d'abandonner sa charte en vertu de la Loi des Compagnies de Québec.Montréal, le 16ème jour de mars 1955.Le Secrétaire, 39479-0 LUCIEN GAUVIN.Compagnies autorisées à faire des affaires (Sec.P.207-55) Avis est, par les présentes, donné que \"New Holland Machine Company\" a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères S.R.Q., 1941, chapitre 279.Le bureau principal de ladite compagnie dans la Province est à 2000 édifice AIdred, 507 Place d'Armes, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans toutes procédures prises contre elle, est M.W.H.Laidley, de ladite cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 24e jour de mars 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39475 JEAN BRUCHÉSI.(Sec.P.231-55) Avis est, par les présentes, donné que \"Ta-patco, Limited\" a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères S.R.Q., 1941, chapitre 279.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province est en la ville de Ayer's Cliff, district de Saint-François.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans toutes procédures prises contre elle, est M.Haydon Hall, de ladite ville de Ayer's Cliff.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 24e jour de mars 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39475 JEAN BRUCHÉSI.Charter \u2014 Surrender of NOTICE Bureau d'Assistance Sociale aux Familles Notice is given that the \"Bureau d'Assistance Sociale aux Familles\", a corporation constitued under the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter in accordance with the Quebec Companies' Act.Montreal, this 16th, day of March, 1955.LUCIEN GAUVIN, 39479 Secretary.Companies Licensed to do Business (P.Sec.207-55) Notice is hereby given that \"New Holland Machine Company\" has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act R.S.Q., 1941, chapter 279.The principal office of the said companv in the Province is 2000 Aldred Building, 507 Place d'Armes, in the city and judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.W.H.Laidley, of the said city of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary this 24th day of March, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39475-0 Assistant Provincial Secretary.(P.Sec.231-55) Notice is hereby given that \"Tapatco, Limited\" has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, R.S.Q., 1941, chapter 279.The principal office of the said company in the Province is at the town of Ayer's Cliff, in the district of St.François.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.Haydon Hall, of the said town of Ayer's Cliff.Given at the office of the Provincial Secretary this 24th day of March\", 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39475-0 Assistant Provincial Secretary.Curatelle publique Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal Succession vacante de Claude Labbé, en son vivant de Montréal.Le soussigné donne avis que cette succession a été déclarée vacante en vertu d'un jugement rendu le 30 septembre 1953, par un juge de la Public Curatorship Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal Vacant estate of Claude Labbé, in his lifetime of Montreal.The undersigned gives notice that these estates has been declared vacant in virtue of a judment rendered September 30th, 1953, by a Judge of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 1027 cour supérieure siégeant à Montréal, dans le the Superior Court, sitting at Montreal, in the district de Montréal, que, sous l'autorité de la Ndistrict of Montreal, that he is, under authority of loi de la curatelle publique (9 Geo.VI, c.62), the Public Curatorship Act, (9 Geo.VI, c.62), il est curateur d'office à cette succession, et qu'il Curator ex officio to these estates and that he recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de shall receive, at the address mentioned below, toute dette envers la succession et la preuve the payment of all debts owing the estate and de toute réclamation contre elle.proof of all claims against said estates.LE CURATEUR PUBLIC, PUBLIC CURATOR, 187, rue Sainte-Catherine (ouest) 187, Sainte-Catherine Street (West), 39480-o Montréal 18.39480 Montreal 18.Département des Affaires municipales Department of Municipal Affairs Annexion à la ville de Marieville A qui les présentes peuvent concerner: Avis est, par les présentes, donné que, par l'arrêté en conseil N° 287, du 17 mars 1955, et conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi des cités et villes, il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil d'autoriser le conseil municipal de la ville de Marieville à exécuter le règlement N° 239 adopté par son conseil municipal, le 14 juillet 1954, et de décréter que, à compter de la date de la publication du présent avis, le territoire mentionné audit règlement et écrit ci-dessous est détaché de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir, dans le comté de Rouville, et annexé à la ville de Marieville.Ce territoire est le suivant : Un territoire faisant actuellement partie de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir comprenant en référence au cadastre officiel de la dite paroisse les lots ou parties de lot ainsi que les chemins, rues, ruelles, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant d'un point sur le côté sud de la rue Saint-Césaire à une distance de mille pieds (1000.0') mesurée sur ledit côté sud de la rue Saint-Césaire à partir du côté est de la rue Séraphin en allant vers l'est; de là, passant successivement par les lignes suivantes: le long du côté sud du chemin Saint-Césaire en allant vers l'est sur une distance de mille cinq cent trente-neuf pieds et sept dixièmes (1539.7'); une ligne faisant un angle intérieur de 100°57' avec la précédente et traversant les lots 156 et 154; une ligne faisant un angle intérieur de 171 °16' avec la précédente et traversant le lot 157; la ligne separative des lots 151 et 152 sur une distance de mille cinq cent quatre-vingt-neuf pieds (1589') jusqu'à la limite actuelle de la ville de Marieville laquelle est une ligne droite passant par le point de départ ci-dessus décrit et un point de la ligne separative des lots 150 et 151 à une distance de quatre arpents (4 arp.) mesurée le long de ladite ligne à l'est de la rue Marieville et enfin ladite limite actuelle de la ville de Marieville en la suivant vers le nord jusqu'au point de départ; lequel territoire à être détaché de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir dans le comté municipal de Rouville, pour être annexé à la ville de Marieville en vertu du règlement N° 239 de la dite ville conformément à la loi des citée et villes.Québec, ce 26 mars 1955.Le Ministre des Affaires municipales, 39487-o YVES PRÉVOST, C.R.Annexation to the town of Marieville To whom these presents may concern: Notice is hereby given that by Order in Council No.287, March 17th, 1955, and pursuant to the provisions of section 43 of the Cities and Towns Act, His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to authorize the town Municipal Council of Marieville, to carry into effect by-law No.239, adopted by its Municipal Council, on July 14th, 1954, and to enact that as from the date of publication of this notice, the territory mentioned in said by-law and described hereinunder, is detached from the parish municipality of Saint Marie-de-Monnoir, in the county of Rouville, and annexed to the town of Marieville.The said territory is the following: A territory presently forming part of the parish municipality of Saint Marie-de-Monnoir comprising, with reference to the official cadastre of the said parish, lots or parts of lots as well as the roads, streets, lanes, streams or parts thereof included within the following boundaries: to wit: commencing at a point on the south side of Saint Césaire Street, at a distance of one thousand feet (100010') measured on the said south side of Saint Césaire Street as from the east side of Séraphin Street, eastwards; thence, passing successively along the following lines: along the south side of Saint Césaire road, eastwards, along a distance of one thousand five hundred and thirty-nine and seven tenths feet (1539.7'); a line forming an inward angle of 100° 57' with the former and extending across lots 156 and 154; a line forming an inward angle of 171° 16 with the former and extending across lot 157; the dividing line of lots 151 and 152 along a distance of one thousand five hundred and eighty-nine feet (1589') as far as the actual boundary line of the town of Marieville, which boundary is a straight line passing along the point of commencement described hereinabove and a point of the dividing line of lots 150 and 151 at a distance of four arpents (4 arps.) measured along the said line east of Marieville Street, and finally the said actual boundary line of the town of Marieville northwards as far as the point of commencement; which territory is to be detached from the parish municipality of Saint Marie-de-Monnoir in the Municipal county of Rouville, in order that it be annexed to the town of Marieville, pursuant to By-law No.239 of the said town, in accordance with the Cities and Towns Act.Quebec, this March 26th, 1955.YVES PRÉVOST, Q.C., 39487 Minister for Municipal Affairs. 1028 ' GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 Département de l'Agriculture Avis est donné que le ministre de l'Agriculture a autorisé la formation d'un cercle agricole dans le comté d'Abitibi-Est, sous le nom de \"cercle agricole de la paroisse de St-Hcnri de Lamoran-dière\", conformément à la loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.118).Daté du bureau du ministre de l'Agriculture, le 15 mars 1955.Le Sous-ministre de l'Agriculture, 39488-o RENÉ TRÉPANIER.Department of Agriculture Notice is given that the Minister of Agriculture has authorized the formation of a Fanners' Club in the county of Abitibi-East, under the name of \"Farmers' Club of the parish of St-Henri de Lamorandière\", pursuant to the Farmers' Club (R.S.Q.1941, chap.118).Dated at the office of the Minister of Agriculture, the 15th day of March 1955.RENÉ TRÉPANIER, 39488 Deputy Minister of Agriculture.Département de l'Instruction Publique N° 1335-54.Québec, le 12 mars 1955.Demande est faite d'ériger en municipalité scolaire distincte, pour les protestants seulement, le territoire actuellement sous la juridiction des syndics d'écoles protestants de Pointe-aux-Trembles.Le Surintendant de l'Instruction publique, 39459-11-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 121-55.Québec, le 11 mars 1955.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Bruno paroisse, comté de Chambly, un certain territoire comprenant une superficie de 1 arpent prise à même le lot N° 310 ainsi qu'une superficie de 1 arpent prise à même le lot N° 309, tous du cadastre officiel de la paroisse de St-Bruno pour l'annexer à la municipalité scolaire de St-Basile-le-Grand, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 39460-1 l-2-o O.1.DÉSAULNIERS.N° 1249-50.Québec, le 22 mars 1955.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire d'Inverness, dans la comté de Mé-gantic, les lots 536, 537, 538, 541 du rang VII du cadastre officiel d'Inverness, pour les annexer à la municipalité scolaire du village d'Inverness, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 39507-12-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 320-55.Québec, le 22 mars 1955.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Plessisville, comté de Mégantic, en celui de \"Ville de Plessisville\", dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 39508-12-2-o O.J.DÉSAULNIERS.Department of Education No.1335-54.Quebec, March 12th, 1955.Application is made to erect into a separate school municipality for Protestants only, the territory presently,.under the jurisdiction of the Protestant School Trustees of Pointe-aux-Trem-bles.O.J.DÉSAULNIERS, 39459-11-2 Superintendent of Education.No.121-55.Quebec, March 11th, 1955.Application is made to detach from the school municipality of St.Bruno parish, county of Chambly, a certain territory comprising an area of 1 arpent taken from lot No.310 as well as an area of 1 arpent taken from lot No.309, all of the official cadastre of the parish of St.Bruno, in order that it be annexed to the school municipality of St.Basile-lc-Grand, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 39460-11-2 Superintendent of Education.No.1249-50.Quebec, March 22nd, 1955.Application is made to detach from the School Municipality of Inverness, in the county of Mcgantic, lots 536, 537, 538, 541, range VII of the official cadastre of Inverness, in order that they be annexed to the village School Municipality of Inverness, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 39507-12-2 Superintendent of Education.No.320-55.Quebec, March 22nd, 1955.Application is made to change the name of the school municipality of Plessisville, county of Mcgantic, into that of \"Town of Plessisville\", in the same county.O.J.DÉSAULNIERS, 39508-12-2 Superintendent of Education.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la cité de Québec, Quartier St-Roch division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que le lot 4480 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 18 mars 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 39489-0 AVILA BÉDARD.Department of Lands and Forests NOTICE Official Cadastre of the city of Quebec, St.Roch ward registration division of Quebec.Notice is hereby given that lot 4480 is added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, March the 18th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch,\" AVILA BÉDARD, 39489-0 Deputy Minister. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1956, Vol.87, No.12 1029 Département du Travail Avis d'approbation de règlements L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que par l'arrêté en conseil numéro 279 du 17 mars 1955 (section \"E\") la constitution et les règlements généraux et spéciaux du Comité paritaire du commerce de détail de Chicoutimi^ approuvés par les arrêtés en conseil numéros 1175-À du 6 novembre 1952 et 1293-D du 15 décembre 1952, ont été annulés et abrogés et qu'une nouvelle constitution et de nouveaux règlements généraux et spéciaux, adoptés par ledit Comité paritaire à son assemblée tenue le 22 novembre 1954, ont été approuvés.Le siège social du Comité paritaire est situé dans la cité de Chicoutimi.En vertu de la Loi, les dispositions suivantes des nouveaux règlements spéciaux dudit Comité paritaire ont été déclarées obligatoires: Art.21.\u2014 Tenue du registre.\u2014 Conformément au paragraphe \"g\" de l'article 20 de la Loi, le Comité paritaire rend obligatoire pour tout employeur professionnel régi par le décret numéro 996 du 2 octobre 1952 et amendements, la tenue d'un registre où sont indiqués les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa qualification ou classification, l'heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l'époque de paiement, ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l'application du décret.Art.22.\u2014 Rapport mensuel.\u2014 Conformément au paragraphe \"k\" de l'article 20 de la Loi, le Comité paritaire oblige tout employeur professionnel régi par le décret numéro 996 du 2 octobre 1952 et amendements, à lui transmettre un rapport mensuel par écrit, signé par lui-même ou par une personne responsable à son emploi, sur lequel doivent être indiqués les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa qualification ou classification, le nombre d'heures de travail régulières ou supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé.Ledit rapport doit être transmis au Comité paritaire le ou avant le 10 de chaque mois et doit couvrir le mois précédent.L'employeur professionnel peut obtenir du Comité paritaire les formules nécessaires pour la préparation dudit rapport.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 26 mars 1955.39490-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que le Comité paritaire des barbiers, coiffeurs et coiffeuses des Trois-Rivières et district lui a présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil les modifications suivantes à la section \"B\" du décret numéro 1040 du 4 août 1948 et amendements, relatif Department of Labour Notice of approval of by-laws The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that, by Order in Council No.279 of March 17th, 1955 (part \"E\"), the constitution and general and special by-laws of the Comité paritaire du Commerce de Détail de Chicoutimi, approved by Orders in Council Nos.1175-A of November 6th, 1952 and 1293-D of December 15th, 1952, have been annulled and repealed and that a new constitution and new general and special by-laws, adopted by the said Parity Committee at a meeting held November 22nd, 1954, have been approved.The head office of the Parity Committee is in the city of Chicoutimi.In pursuance of the Act, the following provisions of the new special by-laws of the said Parity Committee have been rendered obligatory: Art.21.\u2014 Keeping of a register.\u2014 Pursuant to subsection \"g\" of section 20 of the Act, the Parity Committee renders obligatory for every professional employer governed by the decree No.996 of October 2nd, 1952, and amendments, the keeping of a register giving the name in full address of all employees in his employ, their qualification or classification, the exact time at which the work was begun, interrupted, resumed and ceased each day, the nature of such work and the wages paid, with mention of the mode and period of payment, as well as all other particulars deemed useful to the enforcement of the decree.Art.22.\u2014 Monthly report.\u2014 Pursuant to subsection \"h\" of section 20 of the Act, the Parity Committee requires every professional employer governed by the decree No.996 of October 2,1952, and amendments, to submit to it a monthly report in writing, signed by himself or by an authorized person in his employ, in which the following shall be mentioned: the name in full and address of all employees in his employ, their qualification or classification, the number of regular or overtime hours worked each week, the nature of the work and the wages paid.The said report shall be submitted to the Parity Committee on or before the 10th day of each month and shall cover the preceding month.The professional employer may obtain the necessary report forms from the Parity Committee.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 26th, 1955.39490-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the Parity Committee of Barbers, male and female hairdressers of the district of Trois-Rivières has petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to Part \"B\" of the decree No.1040 of August 4th, 1948, and amendments, relating to the barber- 1030 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans la région des Trois-Rivières.1° Les mots suivants seront ajoutés à la liste des prix minima de la zone III apparaissant au paragraphe \"a\" de l'article IV: \"A louiseville: Coupe de cheveux.$0.75 Shampooing régulier.0.50\" 2° Les mots suivants seront ajoutée à la suite de rémunération des heures de travail pour la zone III, paragraphe \"a\" de l'article V : \"A Louiseville, il n'y aura pas de travail le lundi excepté lorsqu'il y aura une fête chômée pendant la semaine.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.\u2022 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 26 mars 1955.39490-o ing and hairdressing trades in the district of Trois-Rivières.1.The following words will be added to the lits of minimum prices for zone III.appearing in subsection \"a\" of section IV: \"In Louiseville: Haircut.$0.75 Regular shampoo.0.50\" 2.The following words will be added after the enumeration of working hours for zone III, subsection \"a\" of section V: \"In Louiseville, there is not work on Monday, except when an observed holiday falls in the week.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 26th, 1955.39490-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (R.S.Q.1941, chapitre 163 et amen-' dements), que le Comité paritaire de l'Industrie de la Sacoche de la Province de Québec lui a présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil la modification suivante au décret N° 1197 du 25 octobre 1951, relatif à l'industrie de la sacoche dans la province de Québec: Le deuxième alinéa de l'article IX sera remplacé par les suivants.\"Les employeurs doivent accorder, à tous salariés des métiers ci-après mentionnés les six (6) jours de fêtes légales suivants, avec salaire: l\\e Vendredi-Saint, l'Ascension, la St-Jean-Baptiste, la Fête du Travail, Yom Kippur et Noël.Si l'un ou l'autre de ces jours de fêtes, autre que le jour de Noël, tombe un samedi ou un dimanche, il n'est pas rémunéré.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 26 mars 1955.39490-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the Parity Committee of the Handbag Industry of the Province of Quebec has petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendment to the decree No.1197 of October 25th, 1951, relating to the handbag industry in the Province of Quebec.The second paragraph of section IX will be replaced by the following: \"The employer shall grant all employees in the abovementioned crafts the following six legal holidays with pay, namely, Good Friday, Ascension Day.St.John the Baptist Day, Labour Day, Yom Kippur, and Christmas.If any such holiday, except Christmas falls on a Saturday or Sunday, that the said holiday or holidays will not be paid for.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 26th, 1955.39490-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité paritaire du commerce de la quincaillerie, district de Québec, établi en exécution du décret numéro 1090, du 7 mars 1940, et amendements, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 279 du 17 mars 1955, section \"A\", le tout conformément a.ux dispositions de la Loi de la Convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that, the Joint Committee of the Hardware Trade, Quebec District, formed under decree number 1090, of March 7th, 1940, and amendments, has been authorized by a by-law.approved by Order in Council number 279 of March 17th, 1955, part \"A\", pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereafter mentioned : QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 1031 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 16 mars 1955 au 16 mars 1956; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 1090 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à l/2 de 1% des salaires, bonis ou allocations payés à leurs salariés assujettis audit décret.b) Les salariés régis par ledit décret numéro 1090 et amendements doivent payer au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% de leurs salaires, bonis et allocations.c) Les artisans régis par le décret numéro 1090 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à de 1% du salaire établi pour le salarié le moins rémunéré, suivant leur emploi, tel que stipulé dans le décret numéro 1090 et amendements.2.Mode de perception Les cotisations sont payables entre le 1er et le 10 de chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, à même le salaire de chacun de ses salariés, les sommes dues au Comité paritaire, à titre de prélèvement.A chaque mois, l'employeur professionnel doit fournir au Comité paritaire un rapport détaillé indiquant, sur les formules mises à sa disposition par ledit Comité paritaire, les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa qualification ou classification, le nombre d'heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé.Ce rapport dûment signé par l'employeur professionnel doit être accompagné des cotisations payables au Comité paritaire par ledit employeur professionnel et par ses salariés; toutes ces sommes doivent être payées en deniers ayant cours légal dans la province de Québec.Le Comité paritaire a le droit d'exiger l'asser-mentation des rapports mensuels des employeurs professionnels chaque fois qu'il le juge à propos.L'artisan doit payer sa cotisation au Comité paritaire avant le 10 de chaque mois.3.Rapport financier Selon les termes de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations' financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus par le Comité paritaire du Commerce de la Quincaillerie, district de Québec, pour la période comprise entre le 16 mars 1955 et le 16 mars 1956.1.Assessments The period of levy extends from March 16th, 1955, to March 16th, 1956, and is laid in the following manner: a) The professional employers governed by the decree number 1090, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to 1/l of 1% of the wages, bonuses or allocations paid to their employees governed by the said decree.b) The employees governed by the said decree N° 1090, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to ]/2 of 1% of their wages, bonuses or allowances.c) The artisans governed by the decree No.1090, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Yi of 1% of the lowest wage rate established for employees, according to their category, as stipulated in the decree number 1090, and amendments.2.Mode of collection The assessments are payable every month, between the 1st and the 10th day of each month.The professional employer shall collect, at the end of each week, from the wages of each one of his employees, the assessments owed to the Parity Committee.Every month, the professional employer shall forward to the Parity Committee a complete report indicating, on forms supplied by the said Committee, the name in full and address of every employee in his employ, his qualification or classification, the number of regular and overtime hours worked each week, the nature of the work and the wages paid.This report duly signed by the professional employer, shall be sent together with the assessments payable to the Parity Committee by the said professional employer and by his employees: al such suras shall be paid with money that is current in the Province.The Parity Committee has the right to exact sworn monthly reports from professional employers when deemed advisable.Artisans shall pay their assessments to the Parity Committee before the 10th of the month.3.Financial Report Under the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit to the Minister of Labour a quarterly report of its financial activities, on the following dates: March 31st, June 30th, September 30th and December 31st.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of the Hardware Trade, Quebec District, for the period comprised between March 16th, 1955 and March 16th, 1956.Comité paritaire du commerce de la Quincaillerie District de Québec Joint Committee of Hardware Trade Quebec District Estimé.des recettes et des déboursés probables Estimate of the receipts and disbursements for pour la période comprise entre le 16 mars the period between March 16th, 1955, and 1955 et le 16 mars 1956.March 16th, 1956.Recettes: Cotisations {]/2 de 1%): Employeurs professionels.$3,250.00 Salariés.3,250.00 Receipts: Assessments (H of 1%) : Professional employers.$3,250.00 Employees.3,250.00 86,500.00 $6,500.00 1032 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 Déboursés: Salaires: Secrétariat et inspection.$4,500.00 Frais de déplacement : Inspection.125.00 Bureau des Examinateurs.350.00 Loyer et éclairage.200.00 Frais judiciaires et professionnels.375.00 Impression et papeterie.200.00 Poste, téléphone et télégramme.100.00 Intérêts, échange et agios.10.00 Jetons de présence.400.00 Taxes d'affaires et d'eau.10.00 Assurance et cautionnement.7.50 Divers.222.50 $6,500.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 26 mars 1955.39490-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité paritaire de la Construction des Comtés de Terrebonne et Labelle, établi en exécution du décret numéro 657, du 13 mai 1948, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 279, du 17 mars 1955, section \"F\", le tout, d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er avril 1955 au 31 mars 1956; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: o) Les employeurs professionnels assujettis au décret numéro 657 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% des salaires et des pourcentages payés à leurs salariés.b) Les artisans assujettis au décret numéro 657 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré dans leur métier.c) Les salariés régis par le décret numéro 657 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 3^ de 1 % de leur salaire et pourcentage.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport indiquant les heures de travail, l'argent pergu au cours de la semaine et les sommes versées au Comité paritaire.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports, accompagnés des cotisations, soient remplis et retournés mensuellement au Comité paritaire avant le 10 du mois suivant l'expiration de la période pour laquelle ils sont exigibles.Tous les employeurs professionnels régis par le décret doivent percevoir à la fin de chaque semaine, les cotisations imposées aux salariés régis par !ç décret, à même le salaire qu'ils sont Disbursements: Salaries: Secretary's office and inspection.$4,500.00 Traveling expenses \u2014 inspection.125.00 Board of examiners.350.00 Rent and lighting.200.00 Judicial and professional fees.375.00 Printing and stationery.200.00 Postage, telephone and telegraph.100.00 Interest, exchange and agios.10.00 Meeting expenses.400.00 Business and water taxes.10.00 Insurance and Surety Bond.7.50 Miscellaneous.222.50 $6,500.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 26th, 1955.39490-o NOTICE OF LEVY - The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Building Industry Joint Committee of Terrebonne and Labelle Counties, formed under decree number 657 of May 13th, 1948, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 279 of March 17th, 1955, part \"F\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Assessments The period of levy extends from April 1st, 1955, to March 31st, 1956, it is laid in the following manner; a) The professional employers governed by the decree No.657 and amendments shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Y of 1% of the wages and percentages paid to their employees.b) The artisans governed by the decree No.657 and amendments shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Y of 1% of the lowest wage rate fixed in the decree for journeymen in their trade.c) The employees governed by the decree No.657 and amendments shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Y of 1% of their wages and percentage.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms giving the hours of labour, the money collected during any one week, and the sums sent to the Parity Committee.The professional employer shall see to it that the reports, together with the assessments, be sent to the Parity Committee before the 10th day of the month following the date of expiration of the period for which they are requirable.All professional employers governed by the decree shall collect, at the end of each week, the assessments of the employees governed by the decree, and forward same, together with their QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 1033 tenus de leur payer et les faire parvenir au Comité paritaire en même temps que leurs propres cotisations.Le rapport de chaque employeur professionnel doit être signé avant d'être adressé au Comité paritaire.Ce Comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire de la construction des comtés de Terrebonne et Labelle, pour la période comprise entre le 1er avril 1955 et le 31 mars 1956.Comité paritaire de la Construction des comtés de Terrebonne et Labelle État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er avril 1955 et le 31 mars 1956.Recettes: Cotisations {%.de 1%): Employeurs professionnels.$12,440.00 Salariés.12,440.00 Artisans.1,310.00 Honoraires d'examen.949.00 Placements, pénalités et divers.581.00 $27,720.00 Déboursés: Administration en général: Salaire des employés, inspection, frais de déplacement, loyer, taxes, éclairage, timbres-postes, téléphone, entretien du bureau, administration de banque, etc.$17,987.00 Jetons de présence.1,340.00 Frais de déplacement des membres.2,628.00 Bureau des examinateurs.3,200.00 Frais judiciaires et professionnels.1,000.00 Impressions, papeterie, vérification et divers.900.00 Assurance-chômage.165.00 Commission d'Apprentissage.500.00 $27,720.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 26 mars 1955.39490-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité paritaire de l'Industrie du Lait de Québec, établi en exécution du décret numéro 481, du 5 mai 1949, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 279 du 17 mars 1955, section \"B\", le tout d'accord avec les disposition de la Loi de la convention collective (Statuts refondus fie Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: own assessments, to the Parity Committee.The report of the professional employer shall be signed before it is sent to the Parity Committee.The Committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.3.Financial report In pursuance of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall make a quarterly report covering its financial operations and remit same to the Minister of Labour on the following dates: March 31st, June 30th, September 30th and December 31st.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Building Industry Joint Committee of Terrebonne and Labelle Counties for the period between April 1st, 1955, and March 31st, 1956.The Building Industry Joint Committee of Terrebonne and Labelle Counties Probable receipts and disbursements for the period between April 1st, 1955 and March 31st, 1956.Receipts: Assessments of t%): Professional employers.$12,440.00 Employees.12,440.00 Artisans.1,310.00 Examination fees.949.00 Investment, penalties, etc.581.00 $27,720.00 Disbursements: General administration: Employees' salaries, inspection, travelling expenses, rent, taxes, lighting, postage, telephone, offi- ce upkeep, bank administration, etc.$17,987.00 Meeting expenses.1,340.00 Travelling expenses of members.2,628.00 Board of examiners.3,200.00 Judicial and professional fees.1,000.00 Printing, Stationery, Audition, Miscellaneous.900.00 Unemployment insu ranee.165.00 Apprenticeship Commission.500.00 $27,720.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister/of Labour.Department of Labour, Quebec, March 26th, 1955.39490-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Parity Committee of the Milk Industry of Quebec, formed under decree number 481 of May 5th, 1949, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 279 of March 17th, 1955, part \"B\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments from the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned : 1034 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 mars 1955, Tome 87, N° 12 1.Cotisation La période de cotisation s'étend de la date de publication du présent règlement dans \\a Gazette officielle de Québec, au 1er mars 1956; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Tous les employeurs professionnels de l'Industrie du Lait assujettis audit décret numéro 481 et amendements, doivent payer au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% de la liste des salaires qu'ils versent à leurs salariés régis par ledit décret.b) Tous les artisans assujettis audit décret numéro 481 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% du salaire établi dans le décret pour le salarié le moins rémunéré dans leur occupation.c) Tous les salariés de l'Industrie du Lait, régis par ledit décret numéro 481 et amendements doivent verser au Comité paritaire une cotisation équivalente à ^ cr two hundred and thirty-seven (Pt.237) of the official cadastre of the parish of Trois-Rivières, county of St-Maurico.Donné à Yamachiche, ce 1er jour du mois «le mars, mil neuf cenl cinquante-cinq.39399- lO-2-o Le Secrétaire-trésorier, OSCAR LECLERC.(liven at Yamachiche, this first day of the month of March, one thousand nine hundred and fiftv-fivc.OSCAR LECLERC, 39399-10-2 Secretary-Treasurer.VENTES PAR SHÈRIFS SHERIFFS' SALES AVIS PUBLIC est par le présent donné que PUBLIC NOTICE is hereby given that the les TERRES ET HÉRITAGES sous-meritionnés undermentioned LANDS and TENEMENTS ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux have been seized, and will be sold at the respect-respectifs, tels que mentionnés plus bas.ive times and places mentioned below.abut hi abut m Canada \u2014 Province of Quebec District of Abitibi Superior Court, t ÉRARD GIASSON, an-No.9548 \\ ^r imitant of Rouyn dis-\\ue ivuuvn-:\\oruiuia, ucman- (trict of Rouvn-Noranda, deur; vs GEORGES TREMBLAY, autrefois plaintiff, vs GEORGES TREMBLAY, hereto-de LaMotte, district d'Abitibi, actuellement fore of LaMotte, district of Abitibi, presently Canada \u2014 Province dc Quebec District d'Abitibi Cour Supérieure, ( p ERARD GIASSON, ren-N° 9548 < tier de Rouyn, district i-Noranda, deman- d'adresse inconnue, défendeur.AVIS DE VENTE of address unknown, defendant.NOTICE OF SALE Lc lot ou les droits acquis sur le lot numéro vingt-six (20) du rang cinq (5) du canton LaMotte avec bâtisses dessus construites circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte dc l'église St-Luc de LaMotte le SAMEDI TRENTE (30) AVRIL 1955 à ONZE (11) heures de l'avant-midi, heure avancée.Lc Shérif, Bureau du Shérif, FERDINAND GERVAIS.Amos, ce 1S mars 1955.39501-12-2-o I«ot, or rights acquired on lot number twenty-six (20) of range five (5) of the township LaMotte, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the church door of St-Luc de LaMotte, SATURDAY, APRIL THIRTIETH, 1955, at ELEVEN (11) o'clock in the forenoon, daylight saving time.FERDINAND GERVAIS, Sheriff's Oilice, Shcrilf.Amos, March 18th, 1955.-39501-12-2 BEDFORD Canada \u2014 Province de Québec District de Bedford Cour Supérieure, bedford r Supérieure, / JOSEPH DESLIER ES, dc- Superior Court./ JOSEPH DESLIERES N° 5994.{ J mandeur, vs F R É 1) E - No.5994.\\ J tilf vs F R É 1) E R iRICK ROY GRANT, défen- \\ ROY GRANT, defends Canada - Province of Quebec Dis! rid of Bedford Superior Court, / JOSEPH DESLIERES,plain- I C K lant.deur.Comme appartenant au défendeur.\"Ce certain morceau de terrain situé dans le canton de Sutton, maintenant inclus dans les limites du village de Sutton, tel que constitué, et connu présentement comme étant le lot numéro sept, cent cinquante-sept (757), du cadastre officiel du canton de Sutton; Avec bâtisses dessus érigées, membres et appartenances.\"Ce certain morceau de terrain, également situé dans le canton de Sutton, maintenant inclus dans les limites du village de Sutton, tel que As belonging to defendant.\"That certain piece of land, lying in the township of Sutton, now comprised within the limits of the village of Sutton, as incorporated, and actually known as lot number seven hundred and fifty-seven, (757) of the official cadastre of the township of Sutton: With buildings thereon erected, members and appurtenances.\"That certain piece of land, also lying in the township of Sutton, now comprised within the limits of the village of Sutton, as incorporated, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 26th, 1955, Vol.87, No.12 1053 constitué, connu comme une partie du lot numéro sept cent cinquante-huit (P.de 758) du cadastre ofliciel du canton de Sutton et décrit comme suit: partant du coin nord-est du lot numéro 757 dudit cadastre, de là allant vers l'est sur une distance d'un pied (1) comme étant la projection de la ligne nord dudit lot N° 757 jusqu'à un point allant alors vers le sud, une ligne droite parallèle à la ligne est dudit lot 757 jusqu'à ce qu'elle atteigne la rive nord delà rivière; de là, vers l'ouest le long de la rive de ladite rivière sur une même distance d'un pied (1) jusqu'au coin sud-est dudit lot 757; de là, vers le nord le long de la ligne est dudit lot mentionné en dernier lieu jusqu'au point de départ.\" Pour être vendu en bloc à la porte de l'église catholique de St-André dc Sutton, le SEPT AVRIL 1955, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif.Bureau du Shérif, A.ST.MARTIN.Palais de Justice, Sweetsburg, Que.393G2-9-2 Canada \u2014 Province de Québec District de Bedford Cour Supérieure, ( \"PvAME RÉGINA BIEN-N° 5857 < ±J VENUE, demanderesse, ( vs POLLENDER FRÈRES LTEE, défenderesse.Comme appartenant au défendeur.\"Un terrain, sis et situé dans ladite ville, connu et désigné comme étant le lot numéro deux cent soixante-onze (271) «lu cadastre officiel de la ville de Farnham, et borné comme suit: au nord par les emplacements de la rue Visitation; à l'ouest par la rue Jacques-Cartier; au sud, par la ligne du chemin de fer et la ligne sud dudit lot; à l'est, par les emplacements de la rue St-Pierre; (la ligne nord dudit lot étant quelque peu excentrique dans sa partie est) sauf cependant et à distraire dudit lot le coin sud-est d'ice-lui de la contenance de quarante pieds de largeur par quatre-vingt-quatre pieds de profondeur, plus ou moins, vendu par Emile Pollender & Al., à James IL Martin par acte reçu par Me S.Noi-seux, notaire, le sept décembre mil neuf cent onze et enregistré à Missisquoi sous le N° 44844 et avec toutes les bâtisses y érigées servant de manufacture et remises ainsi que le contenu de la manufacture et comprenant la machinerie, l'outillage et autres articles servant à l'exploitation du commerce de ladite société Pollender Frères Limitée;\" \"Un terrain, sis et située dans la ville de Farnham, connu et désigné comme étant la partie nord du lot numéro deux cent soixante-six (ptie N° 200) du cadastre officiel de la ville de Farnham, de la contenance (ledit terrain) de douze pieds de largeur par quatre-vingt-quatorze pieds de longueur, plus ou moins, et borné comme suit; au nord, par le lot numéro deux cent soixante-quatre dudit cadastre; à l'est, par la rue St-Picrre; au sud par le résidu dudit lot numéro deux cent soixante-six et à l'ouest par le lot numéro deux cent soixante-onze dudit cadastre sans bâtisses.\" Pour être vendu en bloc, à la porte de l'église catholique de St-Romuald de Farnham, à Farnham, le CINQ AVRIL 1955, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif.Bureau du Shérif.A.ST.MARTIN.Palais de Justice, Sweetsburg.Québec.39301-9-2-o known as being a part of dot number seven hundred and fifty-eight (Pt of 758), of the official cadastre of the township of Sutton, and described as follows; beginning in the north-east corner of lot number 757 of saie cadastre; thence running easterly, a distance of one foot (1) as projection of the north line of said loi No.757 to a point thence southerly running a straight line parallel with the east line of said lot 757 till it strickes the north bank or river; thence westerly along bank of said river, a like distance of one foot (1) to the south-east corner of said lot 757; thence northerly along the east line of said last mentioned lot to the place of beginning.\" To be sold in block at the catholic church door of St-André de Sutton, on the SEVENTH day of APRIL, 1955, at TEN o'clock in the forenoon.A.ST.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Court House, Sweetsburg, Que.39302-9-2 Canada \u2014 Province of Quebec District of Bedford Superior Court, / T^AME RÉGINA BIEN-No.5857 < VENUE, plaintiff, vs (pollender frères LTEE, defendant.As belonging to the defendant.\"A lot of land, situate in the said town, known and designated as being lot number two hundred and seventy-one (271) of the official cadastre of the town of Farnham, and bounded as follows: on the north by the emplacements of Visitation Street; on the west, by Jacques-Cartier Street; on the south, by the railroad line and by the southerly line of the said lot; on the east, by the emplacements of St-Pcter Street; (the northern line of said lot being slightly eccentric in its Eastern part) save however and to withdraw from the southeasterly corner of the same lot a space of forty feet in width by eighty-four feet in depth, more or less, sold by Emile Pollender & Ah, to James H.Martin by deed received by \u2022Me S.Noiseux, notary, on December seventh, nineteen hundred and eleven, and registered as Missisquoi under No.41844 and with all the buildings thereon erected serving as factory and storehouse, as well as the contents of the factory and comprising machinery, equipment and other articles serving for the business operations of the said association Pollender Frères Limitée;\" \"A lot of land, situate in the town of Farnham, known and designated as being the northern part of lot number two hundred and sixty-six (Pt.No.200) of the official cadastre of the town of Farnham, comprising (the said lot of land), a space of twelve feet in width by ninety-four feet in length, more or less, and bounded as follows: on the north, by lot number two hundred and sixty-four of the said cadastre; on the east, by St-Pierre Street, on the south, by the residue of the said lot number two hundred and sixty-six and on the west by lot number two hundred and seventy-one of the said cadastre, without buildings.\" To be sold in block, at the Catholic church door of St-Romuald of Farnham, at Farnham, on APRIL FIFTH, 1955, at TEN o'clock in the forenoon.A.ST.MARTIN, Sheriff's Office Sheriff.Court House, Sweetsbrug, Quebec.39301-9-2 1054 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 wars 1955, Tome $7, N° 12 Canada \u2014 Province de Québec District de Bedford Cour Supérieure, ( t 'OFFICE DU CRÉDIT N°5939.< J-J AGRICOLE DU QUÉ-l BEC, requérant, vs HERVÉ ST-ONGE, intime.Comme appartenant au défendeur.Une ferme sise et située dans le canton de Stukcly, contenant deux cent vingt-cinq acres en superficie, plus ou moins, connue et désignée aux plan et livre de renvoi officiels pour ledit canton, connue étant; Les 50 acres sud du lot 148 bornés comme suit : au nord par le résidu du même lot.à l'est par le lot N° 150.au sud par le lot N'° 382, et à l'ouest par le lot N° -I 17.Les 25 acres sud du lot 119 bornés comme suit; au nord par le résidu du memo loi ainsi que par le lot N 451, à l'est par une partie du lot N° 453.au sud par le lot N° 150, et à l'ouest par une partiedulot X° IIS.Ladite partie de lot correspondant à la moitié sud dc la moitié nord de la moitié esl du lot N° 9 du Oième rang dudit canton, de l'arpentage primitif.Le lot X° 450 contenant cinquante acres en superficie plus ou moins.Le lot 453 contenant cinquante acres en superficie, plus ou moins.Le lot 455 contenant vingt-cinq acres en superficie plus ou moins Le lot 450 contenant vingt-cinq acres en superficie plus ou moins.( Avec les bâtisses sus-érigées.Pour être vendu en bloc à la porte de l'église catholique de Ste Anne de Stukclv.côté de Shefford, le SIX AVRIL, 1955 à DIX heures dc l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le Shérif.Palais de Justice, A.ST.MARTIN.Sweetsburg, Québec.39303-9-2-o gaspé Fieri Facias de Terris District de Gaspé Cour Supérieure, / t LOYD JONES, dc Petite Percé, P.Q.< Rivière ouest, comté de N° 3548 v (Jaspé, demandeur, vs ONI-AS COTE, de Pointe Jaune, comté de Gaspé, défendeur.\"Connu comme étant le lot N° 429-8 du premier rang ouest, canton dc Fox, de forme irrégulière faisant partie du lot N° II, arpentage primitif.Borné au nord par le ruisseau, à l'est par le Golfe, au sud-est par le N° 429-0, au sud-ouest par le chemin de \"la Grève\", à l'ouest par le N° 429-13, mesurant (65') soixante-cinq pieds au nord le long du ruisseau, (80') quatre-vingts pieds au sud-ouest et à l'ouest (55') cinquante-cinq pieds, contenant sept mille cinq cent-dix pieds carrés en superficie.\" Pour être vendu ii la porte de l'église paroissiale de St-Maurice de l'Echourie, comté de Gaspé P.Q.JEUDI le VINGT-HUITIÈME jour d'AYRIL 1955.à TROIS heures dc l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.F.MEAGHER.Percé, P.Q., 19 mars 1955.39502-12-2 HULL District de Hull Cour Supérieure, / CUN LIFE ASSURANCE N° 3554.< COMPANY' OF CANA-v DA, un eorps politique et corporatif «ayant son siège social et principale Canada \u2014 Province of Quebec District of Bedford Superior Court, ( pvUEBEC FARM CREDIT No 5939.< BUREAU, plaintiff, vs ( HERVÉ ST-ONGE, defendant.As belonging to the defendant.A farm situated in the township of Stukcly, containing an urea of two hundred and twenty-five acres, more or less, known and designated on the official plan and book of reference for the sail I township, as being: The 50 acres south of lot 148 bounded as follows: northerly by the residue of said lot, easterly by lot No.450.southerly bv lot No.382, and westerly by lot No.447.The 25 acres south of lot 449 bounded as follows: northerly by the residue of said lot as well as by lot No.451, easterly by a part, of lot No.453, southerly by lot No.450, and westerly by a part of lot No.44S.The said pari of lot corresponding to the south half of the north hall' of the cast half of lot No.9, range six of said township, of the original land surveying.Lot XV 450 containing an area of fifty acres, more or less.Lot 153 containing an area of fifty acres, more or less.Lot 455 containing an area of twenty-five acres, more or less.Lot 450 containing an area of twenty-five acres, more or less.With building erected thereon.To be sold \"en bloc\" at the Catholic church door of St.Anne de Stukely, countv of Shefford, the SIXTH day of APRIL 1955 at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, A.ST.MARTIN, Court House, Sheriff.Sweetsburg, Quebec.39303-9-2 gaspé Fieri Facias de Terris District of Gaspé Superior Court, f t LOYD JONES, of Petite Percé, P.Q.< Rivière west, county of No.3548 l Gaspé, plaintiff; vs ONIAS COTÉ, of Pointe Jaune, county of Gaspé, defendant: \"Known as lot No.429-8 of the first range west of lot No.II, primitive land-surveying.Bounded northerly by the stream, easterly by the Gulf, southeasterly by No.429-6, southwesterly by the road of \"la Grève\", westerly by No.429-13.measuring to the north (65') sixty-five feet along the stream, (80') eighty feet to the southwest and westerly (55') fifty-five feet, containing seven thousand five hundred and ten square feet in superficial area.\" To be sold at the parochial church door of St-Maurice de l'Echourie, county of Gaspé, P.Q., THURSDAY the TWENTY-EIGHTH day of APRIL, 1955 at THREE o'oclock in the afternoon.J.F.MEAGHER.Sheriff's office, Sheriff.Percé, P.Q.March 19th, 1955.39502-12-2-o HULL District of Hull Superior Court, / c UN LIFE ASSURANCE No.3554.< O COMPANY OF CANA-( DA, a body politic anc corporate having its head office and principal place QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 86th; 1955, Vol.87, No.12 1055 place d'affaires en les cité et district de Montréal et CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION, un corps politique et corporatif ayant son siège social et principale place d'affaires en la cité d'Ottawa, province d'Ontario et une place d'affaires en les cité et district de Hull, demandeurs vs ROGER COMTE, «les cité et district de Hull, défendeur.\"Une propriété immobilière connue et désignée comme étant le lot numéro sept cent cinquante-deux de la subdivision officielle «lu lot deux cent quarante-sept (247-752) conformément, aux plan et livre de renvoi officiells du quartier numéro un «le la cité de Hull, et mesurant cinquante pieds (50') de largeur par quatre-vingt-dix-neuf pieds et dix pouces (99'10\") en profondeur avec toutes bâtisses dessus érigées et en voie de construction\".\"Avec un droit de vue sur le lot sept cent cinquante et un dc la subdivision officielle dudit lot deux cent quarante-sept (247-751) Quartier No 1, Hull et sujet à un droit de vue en faveur des lots sept cent cinquante et un et sept cent cinquante-trois dc la subdivision officielle dudit lot deux cent quarante-sept (247-751 et 75.3) Quartier No un, Hull, tel qu'établi par un acte de destination du propriétaire accordé par \"Logements de Hull Tenements Inc.\", par devant Me II.L.Ménard, notaire le 4 octobre 1948, sous le numéro 0053 de son greffe, enregistré au bureau d'enregistrement «le Hull, le 5 octobre 1948, sous le numéro 88274\".Pour être vendu en mon bureau, au Palais de Justice, en la Cité de Hull, district «le Hull, le QUINZIÈME jour d'AVRIL 1955, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.ST.PIERRE.Hull, ce 1er mars 1955.39372-9-2 MONTRÉAL Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: ( t\\AME FLORENCE LA-N° 302452.-j LJ MARRE, épouse sé-v parée de biens de Raymond Pavette, et dûment autorisée par sondit époux, demanderesse vs THOMAS TIMMONS, défendeur.\"Un emplacement situé à la Cité de Jacques-Cartier connu et désigné sous les numéros 428 et 429 «le la subdivision officielle du lot originaire N° 133 «les plan et livre «le renvoi officiel de la paroisse St-Antoine de Longueuil, dans le comté de Chambly, maintenant la cité de Jacques-Cartier avec toutes les bâtisses y érigées notamment celle partant N° 1440 Chemin Chambly, circonstances et dépendances.\" Pour être vendu, au bureau d'enix'gistrement du comté de Chambly, à Longueuil, le VINGT-NEUF AVRIL 1955, à ONZE heures du matin.Le Shérif, Bureau «lu Shérif, CAISSE & HURTEAU.Montréal, 23 mars 1955.39513-12-2-o of business in the city and district of Montreal and CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION, a body politic and corporate having its hea«l office and principal place of business in the city of Ottawa, in the province of Ontario and a place of business in the city and district of Hull, plaintiffs, vs ROGER COMTE, of the city ami district of Hull, defendant.\"An immoveable properly known and described as being lot seven hundred and fifty-two of the official subdivision of lot two hundred and forty-seven (247-752), according to the official plan ami book of reference for Ward One, of the city of Hull, measuring fifty feet (50') in width by ninety-nine feet ten inches (99'10\") in depth with all the buildings thereon erected and in course of construction\".\"With a right of view on lot seven hundred and fifty-one of the official subdivision of said lot two hundred and forty-seven (247-751), Ward One, Hull, and subject to a right of view in favor of lots seven hundred and fifty-one an«l seven hundred and fifty-three of the official subdivision of said lot two hundre«l and forty-seven (247-751 and 753) War«l One, Hull, as established by a deed of destination of the proprietor granted by \"Logements de Hull Tenements Inc.\", before Me R.L.Ménard, notary, on the 4th of October, 194S, under number 6053 of his records registcre«l at the Hull division registry office on the 5th of October, 1948, uiuler number 88274\".To be sold at my office, at the Court House, in the city of Hull, district of Hull the FIFT-EENTH
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.