Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 18 (no 42)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1958-10-18, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tqme 90, N° 42 3521 Vol.90, No.42 Drapeau da la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) j Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Officiai Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 18 octobre 1958 AVIS AUX INTÉRESSÉS Réglementa ,1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues ofBcjelles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.¦ 7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, October 18th, 1958 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates he re i nl >e low set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 3522 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958* Tome 90,N°12 délai pour la réception des avis,.documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces: Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: S7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, REDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502 \u2014 l-52-o Lettres patentes receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7 per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502\u2014 l-52-o Letters Patent (p.G.12444-58) Abmor Realty Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il n été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept juillet 1958, constituant en corporation: Albert Liddell, secrétaire, Harry Blank, Baruch v Pollack et Issie Grcenbaum, tous trois avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger des affaires comme agents d'immeubles et entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Abmor Realty Co.Ltd.\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 300 actions ordinaires de 8100 chacune et 700 actions privilégiées de S100 chacune.1a: siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept juillet 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.48799 P.FRENETTE.(A.G.12444-58) Abmor Realty Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of July, 1958, incorporating: Albert Liddell, secretary, Harry Blank, Baruch Pollack and Issie ( i reel i ban ni.all three advocates, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as real estate.agents and as general contractors, under the name of \"Abmor Realty Co.Ltd.\", with a total capital stock of S100,000.divided into 300 common shares of S100 each and into 700 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of July, 1958.P.FRENETTE» 48799-0 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1968, Vol.90, No.ÂV 3523 (P.G.13208-58) A.& C.Morin Inc.Avis est donné qu'en vertu de» la première partie de la.Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix septembre 1958, constituant en corporation: Paul-Victor Belle-Islc, industriel, Cécilien Bélanger, ingénieur professionnel, tous deux des Trois-Rivières, Jérôme Loranger, notaire, Clément Morin et Alfred Morin, entrepreneurs généraux, tous trois du Cap-de-la-Madeleine, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"A.& C.Morin Inc.\", avec un capital total de $2,000, divisé en 5 actions de $400 chacune.lie siège social de la compagnie sera au Cap-de-la-Madcleine, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le dix septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-o P.FRENETTE.(P.G.13117-58) Aldo Construction Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre septembre 1958, constituant en corporation: Aldo Covicllo, constructeur, Josef Was-serman, agent d'immeubles, tous deux de Montréal, et 1st van Adlcr, agent d'immeubles, d'Outremont, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs, constructeurs, agents d'immeubles et courtiers, sous le nom «le \"Aldo Construction Co.\", avec un capital total de 800,000, divisé en .5,000 actions privilégiées de 810 chacune et 1.000 actions ordinaires «le 810 chacune.Ix> siège social de la compngnicsera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(P.G.13112-57) Antigua Building Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit septembre 1958, constituant en corporation: Guy Girard, notaire, d'Outremont, Noël Galland, constructeur, et Claude Girard, notaire, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction; exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Antigua Building Corporation\", avec un capital total de $75,000, divisé en 250 actions communes «le $100 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.48709-o 1».FRENETTE.(A.G.13208-58) A.& C.Morin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of September, 1958, incorporating: Paul-Victor Belle-Isle, industrialist, Cécilien Bélanger, professional engineer, both of Trois-Rivières, Jérôme Loranger, notary, Clément Morin and Alfred Morin, general contractors, all three of Cap-de-la-Madeleine, for the following purposes: To-carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"A.& C.Morin Inc.\", with a total capital stock of $2,000, divided into 5 shares of $400 each.The head office of the company will be at Cap-de-la-Madeleine, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of September, 1958._ P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13117-58) Aldo Construction Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of September, 1958, incorporating: Aldo Coviello, builder, Josef Wasscrman, realtor, both of Montreal, and Istvan Adler, realtor, of Outremont, for the following purposes: To carry on business as contractors, builders, real estate agents and brokers, under the name of \"Aldo Construction Co.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 5,000 preferred shares of $10 each and into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Genera), this fourth dav of September, 1958.P.FRENETTE, 18799-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13112-57) Antigua Building Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of September, 1958, incorporating: Guy Girard, notary, of Outremount, Noël Galland, builder, and Claude Girard, notary, of Montreal, for the following purposes To carry on business as builders and general building contractors; to operate a business dealing in real estate, under the name of \"Antigua Building Corporation\", with a total capital stock of $75,000, divided into 250 common shares of $100 each and into 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated àt the office of the Attorney General, this eighth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General. 3524 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1968, Tome 90, N* A£ (P.G.13073-58) Avalon Printing Inc.¦ \u2022 Imprimerie Avalon Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix septembre 1958, constituant en corporation: Henri-Wilfrid Laurier, de St-Lambert, William Sanville Aaron, de St-Laurent, Nathaniel Hercules Salomon, de Montréal, tous trois avocats, Marie-Yvonne Hachey, de Montréal, et Mary Homza, de St-Laurent, toutes deux secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: Exercer un commerce d'imprimeurs généraux et éditeurs, sous le nom de \"Avalon Printing Inc.\u2014 Imprimerie Avalon Ire\", avec un capital total de $40,000, divisé en 30,000 actions ordinaires de $1 chacune et 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège sccial de la compagnie sera à Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(P.G.13100-58) Building and Bridges Maintenance Limited Avis est donné qu!en vertu de la première partie de la'Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf septembre 1958, constituant en corporation: Roméo Tardif, nettoyeur, Gérard Lamou-reux, entrepreneur, tous deux de Verdun, et Louis Lymburner, contremaître, de Westmount, pour les objets suivants: ' Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs en construction, sous le nom de \"Building and Bridges Maintenance Limited\", avec un capital divisé en 500 actions ordinaires sans valeur nominale et en 750 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de non moins de $6,250.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-o P.FRENETTE.(P.G.13107-58) Caribe (Realties) Canada Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze septembre 1958, constituant en corporation: Kalman Samuels, Harold Bloomfield, avocats et Frederick Phillips, gérant de bureau, tous de Montréal, pour les objets suivants: Négocier des propriétés immobilières, sous le nom de \"Caribe (Realties) Canada.Limited\", avec un capital-actions divisé en 300 actions sans valeur nominale ou au pair, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $1,500.Le siège social de la compagnie sera à 1434 ouest, rue Ste-Catherine, chambre 203, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(A.G.13073-58) Avalon Printing Inc.Imprimerie Avalon Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor*of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of September, 1958, incorporating: Henri-Wilfrid Laurier, of St.Lambert, William Sanville Aaron, of St.Laurent, Nathaniel Hercules Salomon, of Montreal, all three advocates, Marie-Yvonne Hachey, of Montreal, and Mary Homza,.of St.Laurent, both secretaries, spinsters, for the following purposes: To carry on business as general printers and publishers, under the name of \"Avalon Printing Inc.\u2014 Imprimerie : Avalon Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 30,000 common shares of $1 each and into 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Jacques-Cartier, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of September, 1958.P.FRENETTEr 48799*o \" Acting Deputy Attorney General.(A.G.13100-58) Building and Bridges Maintenance Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the ninth day of September, 1958, 'incorporating: Roméo Tardif, cleaner, Gérard Lamoureux, contractor, both of Verdun, and Louis Lymburner, foreman, of Westmount, for the following purposes: To carry on business as builders and building contractors, under the name of \"Building and Bridges Maintenance Limited\", with a capital stock divided into 500 common shares without nominal value and into 750 preferred shares of a par value of $50 each, and the amount with which the company shall start its operations will be of not less than $6,250.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of September, 1958.P.FRENETTE, * 48799 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13107-58) Caribe (Realties) Canada Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of September, 1958, incorporating: Kalman Samuels, Harold Bloomfield, advocates, and Frederick Phillips, office manager, all of Montreal, for the following purposes: To deal in immoveable properties, under the name of \"Caribe (Realties) Canada Limited\", with a capital stock divided into 300 shares without nominal or par value, and the amount with which the company will commence its operations will be $1,500.* The head office of the company will be at 1434 St: Catherine Street, West, Room 203, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1958, Vol.90, No, MS 3626 (P.G.13192-58) Caverne Laflèche Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix septembre 1958, constituant en corporation: Henri Pigeon, notaire, Lévis Dupré, secrétaire, et Germaine Forest, ménagère, veuve, tous de Pointe-aux-Trembles, pour les objets suivants: Exploiter comme lieu touristique, une caverne souterraine naturelle, sous le nom de \"Caverne Laflèche Inc.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 60 actions de $1,000, chacune.Le siège social de la compagnie sera 12745, rue Notre-Dame, est, Pointe-aux-Trembles, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-0 P.FRENETTE.(P.G.13267-58) Cheryl Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de là province de Québec des lettres patentes, en date du quinze septembre 1958, constituant en corporation:-Sydney Heitner, fabricant, de Ville Mont-Royal, Benn C.Lassner, marchand et Charles Rosen, administrateur, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Transiger des affaires comme courtiers d'immeubles et agents, sous le nom de \"Cheryl Realties Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 10,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1440 rue Towers, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(P.G.12318-57) Club Nautique des Mille-Iles Ltée Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix septembre 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Jean Al lard, industriel, de Sainte-Rose, Lionel Lap 1 an te, industriel, et Alice Laplante, ménagère, épouse contractuel lenient séparée de biens dudit Lionel Laplante, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Former et diriger un club social pour la récréation et la détente de l'esprit et du corps des membres de tel club et de leurs invités, sous le nom de \"Club Nautique des Mille-Iles Ltée\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $900,000.Le siège social de la corporation sera à Sainte-Rose, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-o P.FRENETTE.(A.G.13192-58) Caverne Laflèche Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of September, 1958, incorporating: Henri Pigeon, notary, Levis Dupré, secretary, and Germaine Forest, housekeeper, widow, all of Pointe-aux-Trembles, for the following purposes: To operate as a place for tourists, a natural underground cave, under the name of \"Caverne Laflèche Inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 60 shares of $1,000, each.The head office of the company will be at 12745 Notre-Dame Street, East, Pointe-aux-Trembles, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of September, 1958._ P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13267-58) Cheryl Realties Inc.___.Notice is hereby given that under Part I of - the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of September, 1958, incorporating: Sydney Heitner, manufacturer, of the town of Mount Royal, Benn C.Lassner, merchant, and Charles Rosen, executive, both of Montreal, for the following purposes: To carry on business as real estate brokers and agents, under the name of \"Cheryl Realties Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 10,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at 1440 Towers Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Genera), this fifteenth day of September, 1958._ - P.FRENETTE, 48799-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12318-57) Club Nautique des Mille-Iles Ltée Notice is hereby given that under Part in of the Quebec Companies* Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of September, 1958, to incorporate as a corpora-^ tion without share capital: Jean Allard, industrialist, of Sainte Rose, Lionel Laplante, industrialist, and Alice Laplante, housewife, wife contractually separate as to property of the said Lionel Laplante, and duly authorized by him for the purposes therein, both of Montreal, for the following purposes: To form and conduct a social club for the amusement and relaxation of the mind and body of its members and their guests, under the name of \"Club Nautique des Milles-Iles Ltée\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $900,000.The head office of the corporation will be at Sainte Rose, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Genera), this tenth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General. 3628 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958, Tome 90, N° AS (P.G.13113-68) Danville Sales Agency Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre septembre 1958, constituant en corporation: Boris Garmaise, avocat, Frank Kishner, comptable, et Alva P.Boyd, secrétaire, célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles, meubles, machines, machinerie et quincaillerie, sous le nom 'de \"Danville Sales Agency Inc.\", avec un capital total de $5,000, divise en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(P.G.13157-58) Delibero Bricklaying Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit septembre 1958, constituant en corporation: Irwin S.Brodie, Cyril E.Schwisberg, Théodore H.Polisuk, avocats, et Sonya Schneyer, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme poseurs de briques, constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de \"Delibero Bricklaying Co.Ltd.\", avec un.capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 7477, 18e Avenue, Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(P.G.13076-58) Distribution Moderne Électrique Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux septembre 1958, constituant en corporation '.Guy Rouleau, mineur, de Thetford-Mines, Émilien Rouleau, de Ste-Julie Station, et Jean-Paul Rouleau, de Lyster-Station, tous deux vendeurs, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'accessoires et appareils électriques, sous le nom de \"Distribution Moderne Electrique Ltée\", avec un capital total de $20,000, divisé en 1,000 actions communes de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lyster-Station, comté de Mégantic, district judiciaire de Mégantic.Daté du bureau du Procureur général, le deux septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-0 P.FRENETTE.(A.G.13113-58) Danville Sales Agency Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of September, 1958, incorporating: Boris Garmaise, attorney, Frank Kishner, accountant, and Alva P.Boyd, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To deal in immoveables, furniture, machines, machinery and hardware, under the name of \"Danville Sales Agency Iric*.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 5,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13157-58) Delibero Bricklaying Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of September, 1958, incorporating: Irwin S.Brodie, Cyril E.Schwisberg, Theodore H.Polisuk, advocates, and Sonya Schneyer, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of bricklaying,' building and contracting, under the name of ' \"Delibero Bricklaying Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of tlie company will be at 7477, 18th Avenue, Saint Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13076-58) Distribution Moderne Électrique Ltée.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of September, 1958, incorporating: Guy Rouleau, miner, of Thetford-Mines, Émilien Rouleau, of Ste-Julie Station, and Jean-Paul Rouleau, of Lyster-Station, both salesmen, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in accessories and electrical apparatus, under the name of \"Distribution Moderne Électrique Ltée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Lyster-Station, county of Megantic, judicial district of Megantic.Dated at the office of the Attorney General, this second aay of September, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1958, Vol.90, No.AS 3527 (P.G.12364-58) Donat Delisle &.Fils Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des conpagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze septembre 1958, constituant en corporation: Donat Delisle, entrepreneur-plombier, Maria Talbot Delisle, ménagère, épouse commune en biens dudit Donat Delisle, et dûment autorisée par lui, tous deux de Québec, et Yvon Delisle, entrepreneur-plombier, de Baie-Comeau, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en plomberie, chauffage et réfrigération et comme entrepreneurs, constructeurs et quincailliers, sous le nom de \"Donat Delisle & Fils Limitée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Lé siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le onze septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-o P.FRENETTE.(A.G.12364-58) Donat Delisle & Fils Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of September, 1958, incorporating: Donat Delisle, master plumber, Marie Talbot Delisle, housewife, wife common as to property of the said Donat Delisle, and duly authorized by him, both of Quebec, and Yvon Delisle, master plumber, of Baie Comeau, for the following purposes: To carry on business as master plumbers, contractors in heating and refrigeration, contractors and hard ware m en, under the mame of \"Donat Delisle & Fils Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12925-58) Edmond Courtemanche Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf septembre 1958, constituant en corporation: Gilles Boissonneault, André Surprenant et Guy Boissonneault, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction; exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Edmond Courtemanche Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 4651, rue Chabot, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-o P.FRENETTE.(A.G.12925-58) Edmond Courtemanche Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of September, 1958, incorporating: Gilles Boissonneault, André Surprenant and Guy Boissonneault, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on as builders and general building contractors; to deal in real estate under the name of \"Edmond Courtemanche Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.- The head office of the company will be at 4651 Chabot Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General.(P.G.13071-58) Galerie Artex Inc.- (A.G.13071-58) Galerie Artex Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf septembre 1958, cou sti tu tant en corporation : Thérèse Dorval, secrétaire, célibataire, d'Outremont, Claude Tellier, Pierre Bernier et Jacques Dionne, tous trois avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter une galerie d'art et un commerce de meubles, sous le nom de \"Galerie Artex Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,500 actions communes de $10 chacune et en 1,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2020, rue Union, Montréal, district .judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-o P.FRENETTE.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of September, 1958, incorporating: Thérèse Dorval, secretary, spinster, of Outremont, Claude Tellicr, Pierre Bernier and Jacques Dionne, all three advocates, of Montreal, for the following purposes: To operate an art gallery and furniture business, under the name of \"Galerie Artex Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,500 common shares of $10 each and 1,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 2020 Union Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General. 3528 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1968, Tome 90, N° AS (P.G.13098-58) Garden Park Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze septembre 1958, constituant en corporation : Yvonne Hachey, secrétaire, fille majeure, de Montréal, Henri W.Laurier, de St-Lambert, David H.Wood, de Westmount et William S.Aaron de St-Laurent, tous trois avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Garden Park Corp.\", avec un capital-actions divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et 'en 3,500 actions privilégiées de $10 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $20,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(P.G.13166-58) ~~ Garden view Development Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq septembre 1958, constituant en corporation : Marvin Riback, avocat, Moe Silverstone, commis, et Zygmunt Celichowski, notaire public, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction et développement, sous le nom de \"Gardenview Development Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions privilégiées de $50 chacune et 2,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.^ Daté du bureau du Procureur général, le cinq septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(P.G.13231-58) Gaymar Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix septembre 1958, constituant en corporation: Henri Pigeon, notaire, Levis Dupré, secrétaire, et Germaine Forest, ménagère, veuve, tous de Pointe-aux-Trembles, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Gaymar Realties Inc.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 50 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 12745, rue Notre-Dame, est, Pointe-aux-Trembles, district judiciaire de Montréal._ Daté du bureau du Procureur général, le dix septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-o P.FRENETTE.(P.G.13221-58) Goltex Ltd.(A.G.13098-58) Garden Park Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of September, 1958, incorporating: Yvonne Hachey, secretary, spinster, of Montreal, Henri-W.Laurier, of St.Lambert, David H.Wood, of Westmount, and William S.Aaron, of St.Laurent, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Garden Park Corp.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares having no nominal or par value and into 3,500 preferred shares of $10 each, and the amount with which the company will commence its operations will be $20,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13166-58) .Gardenview Development Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of September, 1958, incorporating: Marvin Riback, advocate, Moe Silverstone, clerk, and Zygmunt Celichowski, notary public, all of Montreal, for the following purposes: ' To carry on the business of a a land, construction and development company, under the name of \"Gardenview Development Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 preferred shares of $50 each and into 2,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of September, 1958.\" P.FRENETTE, 48799-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13231-58) Gaymar Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of September, 1958, incorporating: Henri Pigeon, notary, Levis Dupré, secretary, and Germaine Forest, housekeeper, widow, all of Pointe-aux-Trembles, for the following purposes: To deal in real estate; carry on business as general building contractors, under the name of \"Gaymar Realties Inc.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 50 shares of $100 each.The head office of the company will be at 12745 Notre-Dame Street, East, Pointe-aux-Trembles, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13221-58) Goltex Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIEL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1968, Vol.90, No.12 3529 été accordé par il Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neif septembre 1958, constituant en corporation: Milton L.Klein, avocat, Arthur D.Ruby, comptable agréé et Iown Lantaigne, sténographe, épouse séparée de biens de Roger Lanteigne, tous de Montréal, pour les objets suivants: Importer, exporter et faire le commerce d'appareils et accessoires électriques, meubles et fournitures de maison, porcelaines et coutellerie, tapis, peintures, textiles, papeterie, toiles, literie, aliments et produits alimentaires, marchandises et articles pour hôtel et restaurant, construction et matériaux de construction, articles électroniques, outils, machinerie, accessoires, pièces d'i-ceux et marchandises similaires; transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Gcltex Ltd.\", avec un capital-actions, divisé en 200 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et 800 actions privilégiées de $10 chacune et le montant avec lequel la compagnie commencera ses activités sera de $1,800.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(P.G.13132-58) Heft and Rubin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq septembre 1958, constituant en corporation: Abraham Feiner, Albert Marcus, et Isidore Reuben Prazoff, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et amélioration, sous le nom de \"Heft and Rubin Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.a Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(P.G.12825-58) Houle Auto Parts Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du -vingt août 1958, constituant en corporation: Emile Houle, Maurice Houle, marchands, et Pierrette Houle, ménagère, fille majeure usant de ses droits, tous de Montréal-Nord, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de parties et accessoires d'automobiles, sous le nom de \"Houle Auto Parts Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions communes de $10 chacune et.en 300 actions privilégiées de $.100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 3573, rue Beaubien, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt août 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-0 P.FRENETTE.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of September, 1958, incorporating: Milton L.Klein, advocate, Arthur D.Duby, chartered accountant,'and Iown Lanteigne, stenographer, wife separate as to property of Roger Lanteigne, all of Montreal, for the following purposes: To import, export and deal in electrical appliances and fixtures, home and office furniture and furnishings, china and cutlery, rugs, paints, textiles, stationery, linens, beddings, food and food products, hotel and rsetau rant supplies and equipment, building and building materials, electronics, tools, machinery, accessories and parts thereof and similar merchandise; to carry on the business of an investment company, under the name of \"Goltex Ltd.\", with a capital stock divided into 200 common shares having no nominal or par value and into 800 preferred shares of $10 each, and the amount with which the company will commence its operations will be $1,800.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of September, 1958.P.FRENETTE, M 48799-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13132-58) Heft and Rubin Inc.Notice is hereby given that under Part\" I \"of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day .of September, 1958, incorporating: Abraham Feiner, Albert Marcus and Isidore Reuben Prazoff, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and improvement company, under the name of \"Heft and Rubin Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1%,000 common shares of $1 each and into 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Genera), this fifth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12825-58) Houle Auto Parts Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of August, 1958, incorgorating: Emile Houle, Maurice Houle, merchants, and Pierrette Houle, housekeeper, of full age of majority making use of her rights, all of Montreal-North, for the following purposes: To carry on the business of and deal in automobile parts and accessories, under the name of \"Houle Auto Parts Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into .1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 3573 Beaubien Street, East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Genera), this twentieth day of August, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General. 3530 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1968, Tome 90, N° AS (P.G.12527-58) Ideal Development Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit septembre 1958, constituant en corporation: Michael Garber, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Harry Yohalem Garber, étudiant, tous deux de Westmount, et Irene Rubin, secrétaire, fille.majeure, de Montréal, pour les objets, suivants: Acquérir, acheter, administrer, exploiter, réparer, louer et construire des immeubles et propriétés immobilières et en faire le commerce, sous le nom de \"Ideal Development Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(P.G.12402-581 Jean H.Henle Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze septembre 1958, constituant en corporation: Jean Henry Henle, marchand de gros, Laure Henle, ménagère, épouse séparée de biens dudit Jean Henry Henle, et Marvin Shiller, comptable agréé, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de marchandises pour usage domestique et quincaillerie, sous le nom de \"Jean H.Henle Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires et en 200 actions privilégiées/*toutes de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 4275-7 est, rue Beaubien, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, , 48799 P.FRENETTE.(P.G.13108-58) J.E.G.Habitation Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, i| a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre septembre 1958, constituant en corporation: J.-Edouard Guindon, vendeur, Gilles Bonetto, dessinateur, André Pigeon, commis de bureau, tous trois de Montréal, Jean-Marie Guindon, surintendant, de Saint-Vincent-de-Paul, et Roch Guindon, contremaître, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"J.E.G.Habitation Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 700 actions communes de $10 chacune et en 1,300 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-0 P.FRENETTE.(A.G.12527-58) Ideal Development Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of September, 1958, incorporating: Michael Garber, advocate and Queen's Counsel, Harry Yohalem Garber, student, both of Westmount, and Irene Rubin, secretary, fille majeure, of Montreal, for the following purposes: To acquire, purchase, administer, operate, repair, lease and construct real estate and immoveables and deal with the same, under the name of \"Ideal Development Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12402-58) Jean H.Henle Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of September, 1958, incorporating: Jean Henry Henle, wholesaler, Laure Henle, housewife, wife separate as to property of the said Jean Henry Henle, and Marvin Shiller, chartered accountant, all of Montreal, for the following purposes: To deal in household goods and hardware, under the name of \"Jean H.Henle Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares and into 200 preferred shares all of $100 each.The head office of the company will be at 4275-7 Beaubien Street, East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13108-58) J.E.G.Habitation Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of September, 1958, incorporating: J.-Edouard Guindon, salesman, Gilles Bonetto, draughtsman, André Pigeon, office clerk, all three of Montreal, Jean-Marie Guindon, superintendent, of Saint-Vincent-de-Paul, and Roch Guindon, foreman, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general building contractors under the name of \"J.E.G.Habitation Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 700 common shares of $10 each and into' 1,300 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal, Dffited at the office of the Attorney General, this fourth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1968, Vol.90, No.A2 3531 (P.G.11211-58) J.H.Janelle Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six juin 1958, constituant en corporation: Hervé Jannelle, Jean-Marc Jannelle, marchands, et Carmen Jannelle, secrétaire, célibataire, tous de Napier vil le, pour les objets suivants: Exercer le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"J.H.Janelle Limitée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Napier-ville, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-o P.FRENETTE.(P.G.13209-58) Joluba Realty Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de là Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix septembre 1958, constituant en corporation: Joseph Fishman, marchand, Shirley Simon, secrétaire et Ellen Haggenmueller, commis, toutes deux filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, de construction et d'amélioration, sous le nom de \"Joluba Realty Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(P.G.12040-58) Julie Scarves Incorporated Avis est donné qu'en vertu de^ la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf juillet 1958, constituant en corporation: Louis Feigenbaum, avocat, Morris Shu-ter, comptable, tous deux de St-Laurent et Hyman Solomon, avocat, de Ville Mont-Royal, pour les objets suivants: Fabriquer et exercer le commerce de vêtements et fournitures, sous le nom de \"Julie Scarves Incorporated\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf juillet 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(P.G.13079-58) Kipawa Minerai Explorations Company Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par (A.G.11211-58) J.H.Janelle Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of June, 1958, incorporating: Hervé Jannelle, Jean-Marc - Jannelle, merchants, and Carmen Jannelle secretary, spinster, all of Na-pierville, for the following purposes: To carry on a business dealing in building materials under the name of \"J.II.Janelle Limitée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 4,000 common shares of $25 each.The head office of the company will be at Napierville, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13209-58) Joluba Realty Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of September, 1958, incorporating: Joseph Fishman, merchant, Shirley Simon, secretary, and Ellen Haggenmueller, clerk, both filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Joluba Realty Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and into 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of September, 1958.\u2022 P.FRENETTE, 48799-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12040-58) Julie Scarves Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of July, 1958, incorporating: Louis Feigenbaum, advocate, Morris Shuter, accountant, both of St.Laurent, and Hyman Solomon, advocate, of the town of Mount Royal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel and furnishings, under the name of \"Julie Scarves Incorporated\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common snares of $100 each and into 300 preferred shares of $1C0 each.The head office of the company will be.at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of July, 1958.P.FRENETTE, 48799-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13079-58) Kipawa Mineral Explorations Company Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, Y 3532 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1658, Tome 90, N° kt le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux septembre 1958, constituant en corporation: Harold S.Gerson, géologue et prospecteur, Régi na L.Gerson, marchande, épouse contractuel lement séparée de biens dudit Harold S.Gerson et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes et Samuel Greenstein, prospecteur, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations afin de découvrir des mines et minerais, y compris le gaz naturel, pétrole, huile, leurs produits et sous-produits et les négocier, sous le nom de \"Kipawa Minerai Explorations Company\", avec un capital totaPde $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799 P.FRENETTE.(P.G.13017-58) Kluge & Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix septembre 1958, constituant en corporation: Paul Lamoureux, dessinateur, Jacques La-moureux, avocat, et Joffre Côté, agent d'assurances, tous de Lachine, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de moteurs, machines, instruments et appareils, ainsi que de leurs parties et accessoires, sous le nom de \"Kluge & Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 3333, boulevard Cavendish, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix septembre 1958.¦ L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-o P.FRENETTE.(P.G.13158-58) La Compagnie Ludger LeBlanc Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze septembre 1958, constituant en corporation: Jude Gratton, comptable, Françoise 1 biliaire, secrétaire, et Claire Chalifoux, dactylographe, toutes deux célibataires majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de portefeuille (\"holding\"), sous le nom de \"La Compagnie Ludger LeBlanc Inc.\", avec un capital total de $300,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 29,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Amqui, comté de Matapédia, district judiciaire de Ri-mouski.Daté du bureau du Procureur général, le onze septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-o P.FRENETTE.(P.G.13147-58) La Corporation de Placements Viger Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of September, 1958, incorporating: Harold S.Gerson, geologist and prospector, Regina L.Gerson, marchande, wife contractually separate as to property of the said Harold S.Gerson, and duly authorized by him for the purpose of these presents, and Samuel Greenstein, prospector, all of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals, including natural gas, petroleum, oil and their products and by-products and to deal with the same, under the name of \"Kipawa Mineral Explorations Company\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The.head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13017-58) Kluge & Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of September, 1958, incorporating: Paul Lamoureux, draughtsman, Jacques Lamoureux, advocate, and Joffre Côté, insurance agent, all of Lachine, for the following purposes: To operate an industry and business dealing in motors, machines, instruments and apparatus, as well as their spare parts and accessories, under the name of \"Kluge & Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 3333 Cavendish Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13158-58) La Compagnie Ludger LeBlanc Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters-patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing'date the eleventh day of September, 1958, incorporating: Jude Gratton, accountant, Françoise Dallai re, secretary, and Claire Chalifoux, typist, both spinsters of full age, al of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a holding company under the name of \"La Compagnie Ludger LeBlanc Inc.\", with a total capital stock of $300,-000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 29,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Amqui, county of Matapedia, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of September, 1958.P.-FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13147-58) La Corporation de Placements Viger Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1968, Vol.90, No.!>2 3533 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf septembre 1958, constituant en corporation: Thomas-Louis Boudrault, gérant, François Gagnon, commis, tous deux de Montréal, et Romain Ducharme, manufacturier, de Charlemagne, pour les.objets suivants: Faire affaires comme agents d'immeubles et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"La Corporation de Placements Viger\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40 actions communes de $100 chacune et en 360 actions privilégiées de $100 cheaunc.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau, du Procureur général, le neuf septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-o P.FRENETTE.(P.G, 12679-58) , La Corporation des Gouverneurs Scout de Victoriaville Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de, la province de Québec des lettres patentes, en date du douze septembre 1958, constituant en'corporation sans capital-actions: Leopold Bérubé, voyageur de commerce, Bertrand Garon, hôtelier, et Gilbert Lafrance, industriel, tous de Victoriaville, pour les objets suivants: Promouvoir la formation religieuse, physique, intellectuelle et morale des garçons suivant la méthode Scoute établie par Lord Baden Powell of Gilwell, sous le nom de \"La Corporation des Gouverneurs Scout de Victoriaville inc.\".Le montant auquel sont limités les biens mobiliers que la corporation peut posséder est de $100,000.Le siège social de la corporation sera à Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le douze septembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48799-0 P.FRENETTE.(P.G.12317-58) Laframboise .Thuot Automobile Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize août 1958, constituant en corporation: Gervais Laframboise, garagiste, Clémentine Houle Laframboise, ménagère, épouse commune en biens dudit Gervais Laframboise, et dûment autorisée par lui, Lorenzo Thuot, garagiste, et Marie-Blanche Houle Thuot, ménagère, épouse commune en biens dudit Lorenzo Thuot, et dûment autorisée par lui, tous de Rigaud, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'automobiles et autres moyens de transport; faire affaires comme garagistes, sous le nom de \"Laframboise Thuot Automobile Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions communes de $10 chacune et en 450 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dé la compagnie sera à Rigaud, district judiciaire de Montréal.Da*é_ du bureau du Procureur général, le treize août 1958.L'AssistàiiPprocureur général suppléant, 48799-o P.FRENETTE.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province\"\" of Quebec, bearing date the ninth day of September 1958, incorportaing: Thomas-Louis Boudrault, manager, François Gagnon, clerk, both of Montreal, and Romain Ducharme, manufacturer, of Charlemagne, for the following purposes: To carry on business as real estate agents and general building contractors, under the name of \"La Corporation de Placements Viger\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40 common shares of $100 each and 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12679-58) La Corporation des Gouverneurs Scout de Victoriaville Inc.Notice is hereby given that under Part ni of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of September, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Leopold Bérubé, travelling salesman, Bertrand Garon, hotel-keeper, and Gilbert Lafrance, industrialist, all of Victoriaville, for the following purposes: To promote the religious, physical, intellectual and moral formation of boys according to the method as established by Lord Baden Powell of Gilwell, under the name of \"La Corporation des Gouverneurs Scout de Victoriaville Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at Victoriaville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of September, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12317-58) Laframboise Thuot Automobile Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of August, 1958, incorporating: Gervais Laframboise, garage-keeper, Clémentine Houle Laframboise, housekeeper, wife common as to property of the said Gervais Laframboise, and duly authorized by him, Lorenzo Thuot, garage-keeper, and Marie Blanche Houle Thuot, housekeeper, wife common as to property of the said Lorenzo Thuot, and duly authorized by him, all of Rigaud, for the following purposes: - To carry on the business of and deal in automobiles and other means of transportation; carry on business as garage-keepers, under the name of \"Laframboise Thuot Automobile Inc.\", with a total capital stock of $50,000 .divided into 500 common shares of $10 each and 450 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Rigaud, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of August, 1958.P.FRENETTE, 48799 Acting Deputy Attorney General. 3534 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958, Tome 90, N° Jfl (P.G.12544-58) (A.G.12544-58) ' , Lennex Exports Limited Lennex Exports Limited Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies dè Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Quéftec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the first day du premier août 1958, constituant en corpora- of August, 1958, incorporating: Jacques McNi-tion: Jacques McNicoll, de Ville Mont-Royal, coll, of the Town of Mount Royal, J.Leonard J.Leonard McNicoll, de la ville de Hampstead, McNicoll, of the town of Hampstead, both tous deux industriels, et Mme Francis Will industrialists, and Mrs.Francis Will Dunlop, Dunlop, secrétaire, épouse séparée dé biens par secretary, wife separate as to property by contrat de mariage de William Dunlop, de marriage contract of William Dunlop, of Mont-Montréal, pour les objets suivants: real, for the following purposes: Importer, exporter, faire le commerce de pro- To pimport, export, and deal in products, duits articles et marchandises fabriquées en articles and merchandise made, in whole or in tout ou en pattie de cuir, caoutchouc, métal, part, of leather, rubber, metal, wood, paper, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by-products verre et sous-produits d'iceux, mercerie, animaux, of same, haberdashery, animals, minerals, pre- minéraux, pierres précieuses, liqueurs douces, cious stones, soft drinks, books and periodicals, livres et revues périodiques, peintures, travaux paintings, works of art, food, chemical and artistiques, aliments, produits chimiques et de beauty products, land, sea and forest products, beauté, produits de la terre, de la mer et «le la under the name of \"Lennex Exports Limited\", forêt, sous le nom de \"Lennex Exports Limited\", with a total capital stock of $10,000, divided avec un capital total de $10,000, divisé en 100 into 100 common shares of $100 each, actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4920 The' head office of the company will be at avenue Western, Westmount, district jutliciaire 4920 Western Avenue.Westmount, judicial dis- de Montréal.trict of Montreal.\u2022Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, premier août 195S.this first day of August, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 48799 P.FRENETTE.48709-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.13173-58) (A.G.13173-58) Les Carrières Laurentiennes Ltée Les Carrières Laurcntiennc» Ltée Laurentian Quarries Ltd.Laiircntian Quarries Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing «late the ninth day du neuf septembre 1958, constituant en corpo- of September, 1958, incorporating: Jacques Cor-ration: Jacques Corbeil, entrepreneur, Madeleine beil, contractor, Madeleine Groulx Corbeil, Groulx Corbeil, ménagère, épouse séparée de housewife, wife separate as to property of the biens dudit Jacques Corbeil.de Salaberry-«le- said Jacques Corbeil, of Salaberry-de-Valleyfield, Valley field, et Romuald Corbeil, bourgeois, de and Romuald Corbeil, gentleman, of Montreal, Montréal, pour les objets suivants: for the following purposes: Exploiter des carrières; faire affaires comme To operate quarries; carry on business as entrepreneurs généraux en construction, sous 1c general building contractors, un Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que lc«!it décret, numéro 247, soit modifié comme suit: Le paragraphe \"a\" «le l'article XIV7 est remplacé par le suivant: \"a) Zotie I: Mitaines et gants de travail en cuir seulement: Métiers: Taux à Vheure Coupeur.SI.36 Opératrice (femme).0.81 Tourneur (homme).1.30 Bloqueur (homme).1.30 Examinatrice.0.83 Emballeur (homme).1.30 Travaux généraux: Homme Femme à l'heure 1er trimestre.80.65 80.55 2ème trimestre.0.75 0.60 3ème trimestre.0.85 0.65 4ème trimestre.0.95 0.75 5ème trimestre.1.10 0.81\" L.DÉSILETS, '48822-0 Greffier du Conseil Exécutif.48822-o agreement rendered obligatory by the decree number 247 of February 26, 1948 and amendments, relating to the working glove industry in the province of Quebec, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council an amendment to the said decree; Whereas the petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of August 23, 1958: Whereas the objection set forth has been duly considered its required by the Act; \u2022It is ordained, therefore, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 247, be amended as follows: Paragraphe \"a\" of article XIV is replaced by the following: \"a) Zone I: Leather ivork gloves and mitts only: Crafts: Hate per hour Cutter.81.36 Operator (Female) .'.0.81 Turner (male).1.30 Blocker (male).1.30 Examiner.0.83 Packer (male).1.30 General hand: Male Female per hour 1 st three months.§0.65 $0.55 2nd three months.0.75 0.60 3rd three months.0.85 0.65 4th three months.0.95 0.75 5th three months.1.10 0.81\" L.DÉSILETS, Clerk of the Executive Council.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF S ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Numéro 1014 Section \"D\" Number 1014 Part \"D\" Québec, le 9 octobre 1958.Quebec, October 9, 1958.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concernant une modification au décret relatif Concerning an amendment of the decree relat- aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse ing to the barbering and hairdrcssing trades dans le district de Si-François.in the district of St.Francis.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), «les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans le district de St-François, rendue obligatoire par le décret numéro 255 «lu 5 mars 1953 et amendements, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet «le soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil une modification audit «lécret; Attendu que ladite réquête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition «lu 23 août 1958; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation «le la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 255, soit nuxlifié comme suit: Les dispositions se rapportant à la zone A, apparaissant au paragraphe \"a\" «le l'article VI, sont remplacées par les suivantes: Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Labour Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941.chapter 163 and amendments), contracting parties to the collective labour agreement relating to the barbering and hairdrcssing trades in the district of St.Francis, rendered obligatory by the decree number 255 of March 5.1953 and amendments, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration ami decision of the Lieutenant-Governor in Council an amendment to the said «lecree; Whereas the said petition has been published in the Quebec Official Gazelle, issue of August 23, 1958; Whereas no objection has been made against the approval of the propose*I amendment; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said «lecree, number 255, be amended as follows: The provisions concerning zone A, contained in paragraph \"a\" of article VI, arc replaced by the following: 3554 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1968, Tome 90, N° 42 \"Zone A Lundi: de 1.00 p.m.à 6.00 p.m.Mercredi et vendredi: de 9.00 a.m.sans limite.Mardi et jeudi: de 9.00 a.m.à 6.00 p.m.Samedi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Veille de fêtes chômées: mêmes heures que le vendredi.Cependant, tout travail, excepté le samedi, commencé pendant les heures de travail spécifiées ci-haut, peut être terminé, mais ce temps supplémentaire ne doit jamais dépasser une demi-heure.Cependant, les semaines où il y a un jour de fête chômé, les heures de travail le lundi sont de 9.00 a.m.à 6.00 p.m.\" L.DÉSILETS, 48822-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÊCUTD7 Numéro 1014 Section \"A1' Québec le 9 octobre 1958.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie du camionnage dans l'Ile de Montréal.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie du camionnage dans l'Ile de Montréal, rendue obligatoire par le décret numéro 913 du 16 juin 1948, amendé par les arrêtés en conseil numéros 971-F du 30 juin 1948, 514-E du 12 mai 1949, 368-B du 6 avril 1950, 93-A, 1282-A et 1396-C des 25 janvier, 15 novembre et 13 décembre 1951, 1174-C du 6 novembre 1952, 1296-A du 26 novembre 1953, 1066-C du 3 novembre 1954, 47-A du 18 janvier 1956 et 644-F du 26 juin 1957, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que laidte requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 16 août 1958; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 913, soit modifié comme suit: ' 1° Le paragraphe \"o\" suivant est ajouté à l'article II-A: \"g) Le terme \"chauffeur\" désigne toute personne qui détient un permis de chauffeur ou de conducteur suivant la Loi des Véhicules Automobiles (Statuts refondus de Québec, chapitre 142 et amendements, article 15, paragraphe 3), conduisant un véhicule moteur pour lequel l'artisan ou l'employeur, tel que visé par le paragraphe a) de l'article II, reçoit une rémunération pour son utilité, quel que soit le genre de transport ou de service qu'il donne.Tout service incident relatif au transport ou complétant un service de transport déjà exploité par un employé dûment désigné ou soumis au présent décret est aussi assujetti à ses dispositions.\"Zone A Monday : 1.00 p.m.to 6.00 p.m.Wednesday and Friday: 9.00 a.m.\u2014 no limit.Tuesday and Thursday: 9.00 a.m.to 6.00 p.m.Saturday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Holiday eves: same hours as on Friday.However, except for Saturday, all work begun during the working hours mentioned above may be completed but such overtime work shall never exceed one half-hour.However, in weeks where a holiday occurs, hours of work on Monday shall be from 9.00 a.m.to 6.00 p.m.\" L.DÉSILETS, 48822-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1014 Part \"A\" Quebec, October 9, 1958.Present: The Lieutenant-Governor in council.Concerning amendments to the decree relating to the cartage industry in the Island of Montreal.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the cartage industry in the Island of Montreal, rendered obligatory by the decree number 913 of June 16, 1948.amended by Orders in council numbers 971-F of June 30, 1948, 514-E of May 12, 1949.368-B of April 6, 1950, 93-A, 1282-A and 1396-C of January 25 November 15 and December 13, 1951, 1174-C of November 6, 1952, 1296-A of November 26, 1953,1066-C of November 3,1954,47-A of January 18,1956 and 644-F of June 26, 1957, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-governor in council some amendments to the said decree; Wheceas the petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of August 16, 1958, Whereas the objections set forth have been -duly considered, as required by the Act; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said decree, number 913 be amended as follows: \\ I.The following paragraph \"g\" is added to article II-A: \"g) The term \"driver\" means any person who holds a license as chauffeur or operator in pursuance of the Motor Vehicles Act (R.S.Q., chapter 142 and amendments, sec-tion 15, subsection 3), driving a motor vehicle for the use of which the artisan or employer referred to in paragraph o) of article II receives a remuneration, whatever be the kind of transport or service given.Any incidental service relating to the transport or completing a transport service already operated by an employee duly designated or subject to the present decree is also regulated by the provisions thereof. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18tk, 1968, Vol.90, No.42 3566 Toutefois, ne sont pas visés par la présente However, the present definition does not incul- définition les chauffeurs employés directement de drivers employed directly by a contractor of par un entrepreneur de l'industrie de la construe- the construction industry for his own work (cf- tion pour son propre travail (cf.paragraphe \"d'\\ paragraph \"a\"', article 3, section 2, First chapter article 3, section 2, chapitre premier \u2014 décret \u2014 Decree No.314 of March 27, 1957, relating to numéro 314 du 27 mars 1957, relatif à l'industrie the construction industry and trades in the region et aux métiers de la construction dans la région of Montréal).\" de Montréal).\" 2° Le paragraphe \"a\" de l'article III est rem- 2.Paragraph \"a\" of aiticle III is replaced placé par le suivant: by the following: \"III.Durée du travail: a) I^a semaine normale \"III.Duration of labour: a) The standard de travail ne doit pas excéder cinquante (50) working week shall be one of not more than, heures.Les heursc d'arrivée et de départ de fifty (50) hours.The starting and stopping chaque journée de travail sont déterminées «le hours of the work day shall be mutually agreed gré à gré par l'employeur et les salariés et ne upon by the employer and the employees and doivent pas varier si ce n'est qu'avec le consente- shall not be varied except with the consent of ment des deux parties.\" .both parties.\" L.DÉSILETS, L.DÉSILETS, 48822-o Greffier «lu Conseil Exécutif.48822-o Clerk of the Executive Council.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1014 Section \"E\" ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1014 Part \"E\" Québec, le 9 octobre 1958.Quebec, October 9, 1968.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concernant des modifications au décret relatif Conoernikg amendments of the decree relating à l'industrie de la robe dans la province de to the dress industry in the Province of Quebec.Québec.Attendu que, conformément aux dispositions Whereas, pursuant to the provisions of the «le la Loi de la convention collective (Statuts Collective Agreement Act (Revised Statutes of refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amende- Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the ments), la Commission conjointe de l'industrie Joint Commission for the dress industry of the de la robe de la province de Québec a présenté Province of Quebec has petitioned the Minister au Ministre du Travail une requête à l'effet de of Labour to submit to the consideration and soumettre à l'appréciation et à la décision du decision of the Lieutenant-Governor in Council Lieutenant-gouverneur en conseil certaines some amendments to the decree number 3519 modifications au décret numéro 3519 du 24 of September 24, 1940 and amendments, relating septembre 1940 et amendements, relatif à to the dress industry in the Province of Quebec; l'industrie de la robe dans la province de Québec; Attendu-que ladite requête a été publiée Whereas the petition has been published in dans la Gazette officielle de Québec, édition du 5 the Quebec Official Gazette, issue of July 5, 1068; juillet 1958; Attendu que les objections formulées ont été Whereas the objections set forth have been appréciées conformément à la Loi; duly œnsidered, as required by the Act; Il est ordonné, en conséquence, sur la propo- It is ordered, therefore, upon the recom-sition de l'honorable Ministre du Travail: ¦ mendation of the Honourable the Minister of Labour: Que ledit décret, numéro 3519, soit modifié That the said decree, number 3519, be am end -comme suit: ed as follows: 1° Le paragraphe \"c\" de l'article VI est 1.Paragraph \"c\" of article VI is replaced remplacé par le suivant: by the following: \"c) A l'exception des mois de juillet, août, \"c) Except during the months of July, August, novembre et décembre, l'employeur peut faire November and December, the employer may exécuter du travail le samedi matin, mais il est have work done on Saturday mornings only alors tenu de se conformer rigoureusement aux under the following conditions which must be dispositions suivantes: rigorously followed, to wit: Tout tel travail doit: All such work shall be: i.être rémunéré à raison de salaire et demi ; i.paid for at the rate of time and a half; ii.être exécuté entre 8.00 a.m.et mi«li; ii.performed between the hours of 8.00 a.m.and noon; iii.n'être exécuté qu'à la suite d'un avis écrit iii.done only after the employer gives a à cet effet adressé'par l'employeur à la Commis- prior written notice of Intent to the Joint Com-sion conjointe chargée de la mise à exécution du mission charged with the supervision of the présent décret; present decree; iv.de plus, on doit garantir quatre (4) heures iv.furthermore, four (4) hours of work or de travail ou de rémunération à tout salarié payment therefor shall be granted to each em-requis de travailler le samedi matin et qui se ployee who is called to work and reports for présente au travail, «[u'il y ait du travail ou work, whether work is done or not during each non.\" Saturday morning.\" 2° Les sous-paragraphes \"a\", \"6\" et \"c\" du 2.Sub-paragraphs \"a\", \"6\" and \"c\" of para-paragraphe 1 de l'article X-A sont remplacés graph 1 of article X-A are replaced by the par les suivants: following: 3556 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958, Tome 90, N° 42 a) Après un (1) an de services continus pour leur employeur, à un congé annuel continu et payé d'une durée minimum de quatorze (14) jours, comprenant au moins dix (10) jours de travail.b) S'ils n'ont pas terminé trois (3) mois de services continus à l'emploi de leur employeur, à un congé annuel continu payé d'une durée minimum d'autant de 5/12 de journées de travail qu'ils ont de mois de calendrier de services continus pour leur employeur.S'ils ont terminé trois (3) mois mais pas une ;(1) année de services continus à l'emploi de leur employeur, à tin congé annuel continu payé d'une durée minimum d'autant «le 5/6 de journées de travail qu'ils ont de mois de calendrier de services continus pour leur employeur.c) \"Si, pour quelque raison que ce soit, leur emploi est terminé avant qu'une (1) année de services continus ne soit, complétée, tels salaries, au terme de leur emploi, ont droit à une indemnité pour congé comme suit: Si tels salariés n'ont pas terminé trois (3) mois de services continus, à une somme équivalente à 2% du salaire gagné par tels salariés quand ils étaient à l'emploi de l'employeur pendant cette année de services continus.Si tels salariés ont une période de services de trois (3) mois ou plus, ù une somme équivalente à 4% du salaire gagné par tels salariés quand ils étaient à l'emploi de l'employeur pendant cette année de services continus.\" 3° Le sous-paragraphe \"6\" du paragraphe 3 .de l'article X-A est remplacé par le suivant: \"b) Deux pour cent (2%) du salaire gagné dans la période de services de moins de trois (3) mois lui donnant droit au congé et 4% du salaire gagné pendant la période de services de trois (3) mois ou plus, lui donnant droit au congé, s'il est payé sur toute autre base.\" ., 4° Le dernier alinéa du paragraphe 4-a de l'article XII est remplacé par le suivant: .\"En plus, tel travailleur à domicile doit recevoir une somme équivalente à 31% «le sa rémunération si ce travailleur a plus de trois (3) mois d'expérience et à 32% s'il a moins «le trois (3) mois d'expérience.Ce pourcentage est réparti comme suit: Boni de vie chère, 30%, vacances annuelles payées 4 ou 2% selon le cas.\" .5° L'article XVIII est remplacé par le suivant: ., \"XVIII.Système unique de travail: Il est loisible à tout, employeur «l'établir dans son atelier un système «le rémunération selon la durée «lu travail ou à la pièce soit pour un département «le cet atelier ou pour un ou plusieurs métiers.Toutefois, exception faite «les échantillonneurs ,et des assistants-pressiers et «les apprentis, aucun employeur ne peut mettre en vigueur simultanément dans son établissement pour quelque département ou métier les deux systèmes de rémunération ci-haut mentionnés.Lorsqu'un employeur enfreint les dispositions «lu présent article, la Commission conjointe a le droit de calculer les lacunes de salaire «le tout salarié selon la base qui donne à ce dernier le salaire le plus élevé, soit sur la base de durée «lu travail ou sur la base de travail à la pièce.\" L.DÉSILETS, 48822-0 Greffier du Conseil Exécutif.\"a) After one (1) year's continuous service in the employ of his employer, to a continuous annual vacation with pay for a minimum duration of fourteen (14) days, comprising at least ten (10) working days.b) If the employee has not yet completed three (3) months continuous service in the employ of his employer, to a continuous annual vacation with pay, having a minimum duration of as many 5/12's of working days as the number of calendar months during which he has been continuously in the employ of his employer.If the employee has completed three (3) months but has not yet completed a (1) year's continuous service in the employ of his employer, to a continuous annual vacation with pay, having a minimum duration of as many 5/6's of working days as the number of calendar months during which he has been continuously in the employ of his employer.c) If, for any reason whatsoever, employment of an employee is terminated before a (1) year of continuous service is completed, the said employee shall, at the time the employment is so terminated, be indemnified, in lieu of vacation with pay, as follows: If such employee has not yet completed three (3) months of continuous service \u2014 with a sum equal to 2% of the wages earned by such employee in that portion of the said year of continuous service during which he was in the employ of the employer.If such employee was employed for a period of three (3) months or more \u2014 with a sum equal to 4% of the wages earned by such employee in that portion of the said year of continuous service during which he was in the employ of the employer.\" 3.Sub-paragraph \"6\" of paragraph 3 of article X-A is replaced by the following: \"6) Two per cent (2%) of the wages earned during the period of service of less than three (3) months entitling the said employee to his vacation, and 4% of the wages earned during the period of service of three (3) months or more entitling the said employee to his vacation, if said employee is paid on any other basis.\" 4.The last sub-paragraph of paragraph 4-a of article XII is replaced by the following: \"In addition, each homeworkcr shall be paid a sum equivalent to 34% of such employee's earnings if he has more than three (3) months' experience, and to 32% if he has less than three (3) months' experience.This percentage is constituted as follows: Cost of living bonus, 30%, annual vacation with pay, 4 or 2% us the case may be.\" 5.Article XVIII is replaced by the following: \"XVIII.One system of work: It shall be optional for any employer to conduct any department, or pay any craft in his factory on a time work basis or on a piece work basis.However, excepting sample makers, ossistant pressors and apprentices, it is prohibited for any employer to conduct any one department or pay any one craft in the employer's factory on both a time work basis and a piece work basis.Whenever any employer violates the provisions of this article, the Joint Commission shall have the right to compute any deficiency of wages due to any employee on the basis which will yield the highest remuneration to such employee, whether on a time work basis or on a piece work basis.\" L.DÉSILETS, 48822-0 Clerk of the Executive Council._ QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1958, Vol.90, No, 42 3557 Avis divers Avis est par les présentes donné par les soussignés que le Lieutenant-goUverneur en conseil a adopté, en date du 11 septembre 1958, un arrêté en conseil à l'effet de changer le nom de la municipalité de la partie sud du canton de Marston en celui de \"Municipalité de Piopolis\", comté de Frontenac.Conformément aux dispositions de l'article 48 du Code municipal, ce changement de nom entre en vigueur à compter de la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Piopolis, 4 octobre 1958.Le Maire, DOMINA TRUDEAU.Le Secrétaire-trésorier, 48802-o IRENÉE ROY.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire du Collège de Ste-Ànne de la Pocatière\", en date du 28 septembre 1958, dont le siège social est situé au Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le huit octobre 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48803-o JEAN BRUCHÉSI.- \u2022 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire Desjardins de St-Donat de Montréal\", en date du 23 septembre 1958, dont le siège social est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le huit octobre 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48804-o JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes honné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire St-Damase (St-Michel)\", en date du 23 septembre 1958, dont le siège social est situé en la cité de St-Michel, district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le huit octobre 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48805-o JEAN BRUCHÉSI.(P.G.13261-57) La Corporation Foncière de Montréal Règlement N° V Il est statué par le règlement N°\"V: 1° Que le nombre des directeurs composant le bureau de direction de la compagnie \"La Corporation Foncière de Montréal\" soit augmenté de 5 à 6 directeurs; Miscellaneous Notices Notice is hereby given by the undersigned the Lieutenant-Governor in Council has adopted, under date of September 11, 1958, an Order in Council in order to change the name of the municipality of the southerly part of the township of Marston to that of \"Municipality of Piopolis\", county of Frontenac.Pursuant to the provisions of article 48 of the Municipal Code, this change of name shall come into force as from the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.' Piopolis, October 4, 1958.DOMINA TRUDEAU, Mayor.IRENÉE ROY, 48802 Secretary-Treasurer.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire du Collège de Ste-Anne de la Pocatière\", under date of September 28, 1958, whereof the head office is at the College of Ste.Anne-dc-Ia-Pocatière, county of Kamouraska, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary,, this eighth day of October, 1958.JEAN BRUCHÉSI, 48803 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"L8 Caisse Populaire Desjardins de St-Donat de Montréal\", under date of September, 23, 1958, whereof the head office is at Montreal, judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary* this eighth day of October, 1958.JEAN BRUCHÉSI.48804 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the.third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire St-Damase (St-Michel)\", under date of September 23, 1958, whereof the head office is in the city of St-Michel, judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the Department, of the Provincial Secretary.\u2022 Given at the office of the Provincial Secretary* this eighth day of October, 1958.JEAN BRUCHÉSI, 4S805 Under Secretary of the Province.(A.G.13261-57) La Corporation Foncière de Montréal By-law No.V It is enacted by by-law No.V: 1.That the number of directors forming the hoard of directors of the company \"La Corporation Foncière de Montréal\" be increased from' 5 to 6 directors; 3558 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958, Tome 90, N° 42 2° Que 4 directeurs constituant le quorum à toute assemblée du bureau de direction; 3° Que le règlement N° I de la compagnie, étant les règlements généraux, soit modifié en conséquence et que tous autres règlements, résolutions et décisions de la compagnie contraires au présent règlement sont par les présentes amendés, modifiés et revisés pour donner effet à ce règlement.Copie certifiée du règlement N° V dûment adopté à une assemblée des directeurs de la compagnie tenue le 26ième jour d'août 1958 et approuvé à une assemblée générale spéciale de la compagnie tenue le 26ième jour d'août 1958 par tous les actionnaires de la compagnie détenant entre eux 100% du capital-actions de la compagnie.Montréal, le 19 septembre 1958.Le Secrétaire, 48806-o JACQUES DUSSAULT.(P.G.3289-53) Quebec Catering: Limited Règlement N° 8 Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Quebec Catering Limited\" (ici nommée la compagnie) ce qui suit: 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit, et il est, par les présentes, augmenté de cinq (5) à sept (7) de manière que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de sept (7) directeurs dont trois (3) formeront quorum.2° Qu'en plus des autres officiers de la compagnie, il y aura un président du bureau de direction qui devra être l'officier senior de la compagnie, et devra être élu par le bureau de direction, d'entre ses membres.3° Que la fonction du Président du bureau de direction puisse être remplie en même temps par le Président de la compagnie.4° Le Président du bureau de direction devra posséder les pouvoirs et autorité d'administration dont il est habituellement investi comme officier senior de la compagnie.Il sera un membre cx-efficio de tous les comités existants et président de toutes les assemblées des directeurs et actionnaires de la compagnie.5° Que tous les règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à icelui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés de manière à donner effet à ce règlement.Vraie copie certifiée d'un règlement passé à une assemblée du Ixircau de direction de \"Quebec Catering Limited\", dûment convoquée et tenue à Toronto, le trois juin 1958, et approuvé subséquent ment par la vote d'au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale convoquée aux fins de considérer ledit règlement.(Sceau) Le Secrétaire, 48807 A.R.TOMKINS.(P.G.12588-58) Lafontaine Holdings Limited Règlement N° XXIII étant un règlement qui augmente le nombre des directeurs de la compagnie de trois (3) à quatre (4) Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme le règlement N° XXIII de \"Lafontaine Holdings Limited\", (ici nommée la \"compagnie\") ce qui suit: 2.That 4 directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors; 3.That by-law No.I of the company, being the general by-laws thereof, be amended accordingly and that any other by-laws, resolutions and decisions of the company inconsistent herewith be amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.Certified copy of by-law No.V duly adopted at a meeting of directors of the company held the twenty-sixth day of August 1958 and confirmed, at a special general meeting of the company held the twenty-sixth day of August 1958, by all the shareholders of the company helding among themselves 100% of the share capital of the company.Montreal, September 19, 1958.JACQUES DUSSAULT, 48800 * Secretary.(A.G.3289-53) Quebec Catering Limited By-law No.3 Be it enacted and it hereby is enacted as a By-law of \"Quebec Catering Limited\" (herein called the company) as follows: 1.That the numbef of Directors of the company be.and the same hereby is, increased from five (5) to seven (7) so that the board of directors of the company shall hereafter be composed of seven (7) directors of whom three (3) shall form a quorum.2.That in addition to the other officers of the company there shall be a chairman of the board, who shall be the senior officer of the company, and shall l>e elected by the board of directors from among their number.3.That the office of the chairman of the board may l>e held at the same time by the president of the company.4.The chairman of the board shall have the general powers and administrative authority usually vested in him as the senior officer of the company.He shall be ex officio a member of all standing committees and chairman of all meetings of the directors and shareholders of the company.5.That all prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.Certified a true copy of a by-law passed at a meeting of the board of directors of \"Quebec Catering Limited, duly called and held at Toronto on June third, 1958 and subsequently approved by the vote of at least two-thirds in value of the shares represented by the shareholders present at a special general meeting called for considering the said by-law.(Seal) A.II.TOMKINS, 48807-o Secretary.(A.G.12588-58) Lafontaine Holdings Limited By-law No.XXIII being a By-law increasing the number of directors of the company from three (3) to four (4).Be it enacted and it is hereby enacted as By-law No.XXIII of \"Lafontaine Holdings Limited\", (herein called the \"company\") as follows: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1958, Vol.90, No.42 3559 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de trois (3) à quatre (4) de manière que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de quatre (4) directeurs.2° Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à icelui, sont par les présentes, amendés, modifiés et revisés de manière à donner effet à ce règlement.Vraie copie certifiée du règlement N° XXIII de \"Lafontaine Holdings Limited\", adoptée par les directeurs à une assemblée tenue le 18e jour de juillet 1958, et confirmé à l'unanimité h une assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le même jour.(Sceau) Le Secrétaire, 48808 DENISE M.LANDRY.1.The number of directors of the company be and the same is hereby increased from three (3) to four (4) so that the board of directors shall hereafter l>e composed of four (4) directors.2.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.Certified true copy of by-law No.XXIII of \"Lafontaine Holdings Limited\", adopted by the directors at a meeting held on the 18th day of July, 1958, and unanimously confirmed at a special general meeting of the shareholders held on the same day.DENISE M.LANDRY, 48808-o Secretary.(P.G.12590-57) (A.G.12596-57) Imperial Metal & Waste Co.Ltd.Imperial Metal & Waste Co.Ltd.Un règlement qui diminue le nombre de direc- By-law reducing the number of directors, teurs.\"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, \"Be it enacted and it is hereby enacted as a décrété comme un règlement de \"Imperial Metal by-law of \"Imperial Metal & Waste Co.Ltd.\", & Waste Co.Ltd.\", ce qui suit: as follows: 1° Que le nombre des directeurs de la com- 1.The number of directors of the company pagnic soit et il est, par les présentes, diminué be and the same is hereby decreased from four de quatre à trois de manière que le bureau de to three so that the board of directors of the direction de la compagnie soit dorénavant com- company shall hereafter be composed of three posé de trois directeurs; directors; 2° Tous règlements, résolutions et procédures 2.All prior by-laws, resolutions and proceed- antérieurs de la compagnie incompatibles à ings of the company inconsistent herewith are icelui sont, par les présentes, amendés, modifiés hereby amended, modified and revised in order et revisés de manière à donner effet à ce règle- to give effect to this by-law.\" ment.\" Vraie copie certifiée d'un règlement de \"Im- Certified true copy of a by-law of \"Imperial perial Metal & Waste Co.Ltd.\", dûment décrété Metal & Waste Co.Ltd.\", duly enacted and et passé à une assemblée des directeurs de la passed at a meeting of the directors of the com- compagnie tenue le 30e jour de décembre 1957 pany held on the 30th day of December, 1957 and et approuvé, ratifié et confirmé à une assemblée approved, ratified and confirmed at a meeting des actionnaires de cette compagnie à une of the shareholders of this company at a meeting assemblée tenue le même jour.held on the same day.Le Secrétaire, JOE EDGAR, 48809 JOE EDGAR.48809-o Secretory.(P.G.13911-57) (A.G.13911-57) 24th St.Corporation 24th St.Corporation Règlement N° \"B\" By-law No.\"R\" \"Que le nombre «les «lirecteurs de la compa- \"That the number of the directors of the gnie soit augmenté de trois (3) à quatre (4).\" company be increased from three (3) to four (4).\" Vraie copie certifiée «lu règlement décrété par Certified true copy of by-law enacted by the les directeurs de \"24th St.Corporation\" le 7e directors of \"24th St.Corporation\", on the 7th jour de janvier 1958, et approuvé à l'unanimité day of January, 1958, and unanimously approved à une assemblée générale spéciale des action- at a special, general meeting of the shareholders naires tenue le 7e jour de janvier 1958.held on the 7th day of January, 1958.(Sceau) Le Secrétaire, (Seal) KEN.ZAKUTA, 48810 KEN.ZAKUTA.48810-o Secretary.(P.G.14632-52) (A.G.14632-52) Douglas Bremner Inc.Douglas Uremner Inc.Amendement au règlement #9 Amendment to by-law #9 Nous certifions, par les présentes, que le We hereby certify that by-law #9 of this règlement #9 de cette compagnie a été changé company was changed by deleting the wording: en rayant les mots: \"Les affaires de la compagnie seront adminis- \"The affairs of the company shall be managed trees par un bureau de trois directeurs.\" by a board of three directors.\" et en y substituant en conséquence: and substituting therefore: \"Les affaires de la compagnie seront adminis- \"The affaire of the company shall be managed trees par un bureau de sept directeurs.\" by a board of seven directors.\" 3560 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958, Tome 90, N° J&WWM Je certifie, par les présentes, que le changement dans le règlement #9 a été régulièrement adopté par les directeurs le 4 août 1958, et qu'il a été approuvé à une assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 11 août 1958, à laquelle cent pour cent des actionnaires étaient représentés en personne ou par procuration.12 août 1958.Le Secrétaire, 48811 W.WILSON RATHIE.Bishop Asphalt Papers Limited Règlement \"10\" Un règlement qui autorise la distribution de l'actif de la compagnie Qu'il soit et il est, par les présentes, décrété ce qui suit: 1° L'actif de la compagnie sera distribué au pro rata entre ses actionnaires suivant leurs droits respectifs ou suivant les directives de distribution données à la compagnie par tous les actionnaires.2.Aucun deux officiers ou directeurs de la compagnie sont, par les présentes, autorisés et dirigés, pour, en faveur et au nom de la compagnie, à signer, exécuter et délivrer et apposer le sceau de la compagnie a tous tels actes, ententes, documents, instruments et écrits et faire, exécuter ou faire exécuter et accomplir tous tels actes et choses qu'ils peuvent, à leur discrétion, considérer opportuns aux fins d'effectuer et donner effet à la distribution de son actif entre ses actionnaires conformément aux dispositions susdites du présent règlement.Vraie copie certifiée du règlement \"10\" adopté à une assemblée des directeurs de \"Bishop Asphalt Papers Limited\" tenue le 2 octobre 1958, et approuvé, ratifié et confirmé à l'unanimité par tous les votes donnes à l'assemblée générale spéciale des actionnaires de ladite compagnie convoquée aux fins de la considérer et tenue le même jour.Montréal, P.Q., 10 octobre 1958.Ix» Vice-président, C.P.WYMAN.Le Secrétaire, 48812 A.N.RAYBOULD.(P.G.1276-46) re: Van de North Ltd-Ltée.Règlement N° 38: - changement de bureau-chef: II est par les présentes décrété comme règlement de la compagnie, que la situation du bureau-chef de la compagnie soit changée de la cité de Montréal, district de Montréal, en la cité de St-Hya-cinthe, district de St-Hyacinthe, Province de Québec.CERTIFICAT Je, soussigné, J.Marcel Lemieux, secrétaire de la compagnie \"Van de North Ltd-Ltée.\" certifie par les présentes, que le règlement ci-haut est une vraie copie du règlement numéro 38 de la compagnie, tel qu'adopté par les directeurs de la compagnie à une assemblée dûment convoquée et tenue le 10 septembre 1958 et que ledit règlement a été par la suite dûment sanctionné par les actionnaires de la compagnie à une assemblée générale et spéciale tenue le même jour, par le vote unanime de tous les actionnaires de ladite compagnie, présents à ladite assemblée.Le Secrétaire, 48824-0 J.MARCEL LEMIEUX.I hereby certify that the change in by-law #9 was regularly adopted by the directors on August 4th, 1958, and that it was approved at a special general meeting of the shareholders held on August 11th, 1958, at which one hundred per cent of the shareholders were represented in person or by proxy.August 12, 1958.W.WILSON RATHIE, 4881 l-o Secretary.Bishop Asphalt Papers Limited By-law \"10\" A by-law to authorise the distribution of the Company's assets.Be it and it is hereby enacted as follows: 1.The assets of the company shall be distributed ratcably amongst its shareholders in accordance with their respective rights or in accordance with the directions for distribution given to the company by all the shareholders.2.Any two officers or directors of the company are hereby authorized and directed, for and on behalf and in the name of the company, to sign, execute and deliver, and affix the seal of the company to, all such deeds, agreements, documents, instruments and writings and do and perform or cause to be done and performed all such acts and things as they, in their discretion, may consider to be expedient for the purpose of carrying out and giving effect to the distribution of its assets amongst its shareholders in accordance with the foregoing provisions of this'by-law.Certified to be a true copy of By-law \"10\" adopted at a meeting of the directors of \"Bishop Asphalt Papers Limited\" held on October 2, 1958, and approved, ratified and confirmed unanimously by all the votes cast at the special general meeting of the shareholders of said company called for considering the same and held on the same day.Montreal, P.Q., October 10.1958.C.P.WYMAN, Vice-President.A.N.RAYBOULD, 48812-o Secretary.(A.G.1276-46) re: Van de North Ltd-Ltée.By-law No.38 - change of location of head office: It is hereby enacted as a by-lawof the company, that the head office of the company be moved from the city of Montreal, district of Montreal, to the city of St.Hyacinthe, district of St.Hyacinthe, province of Quebec.CERTLFICATE I, the undersigned, J.Marcel Lemicux, secretary of the company \"Van de North Ltd-Ltée.\", hereby certify that the above by-law is a true copy of By-law number 38 of the company as adopted by the directors of the company at a meeting duly called and held September 10, 1958 and that'the said by-law was duly sanctioned by the shareholders of the company at a special general meeting held the same day, by a unanimous vote of all the shareholders of said company present at said meeting.J.MARCEL LEMIEUX, 48824 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1968, Vol.90, No.1,2 3561 (P.G.13627-57) I) h f.am we Alt Ltd.Règlement N° 22 \"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Dreamwear Ltd.\", ce qui suit: 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de trois à quatre de manière que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de quatre directeurs.2° Quatre directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3° Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie, incompatibles à icelui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés de manière à donner effet à ce règlement.\" Nous, les soussignés, Rubin Klugcr et Dr.Phineas Rabinovitcb, respectivement président et secrétaire de \"Dreamwear Ltd.\", certifions, par les présentes, sous le sceau corporatif de la compagnie que le précédent est une vraie et authentique copie du règlement N° 22 de la compagnie, régulièrement adopté par le bureau des directeurs de ladite compagnie à une assemblée dûment et régulièrement convoquée et tenue au bureau de la compagnie, le 29e jour d'août 1958, le tout selon les manières et formalités requises par la Loi, et qu'à une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie dûment et régulièrement convoquées et tenue au bureau de la compagnie le 29 août 1958, ledit règlement N° 22 a été dûment ratifié, confirmé et approuvé à toutes fins que de droit; et qu'à ladite assemblée générale spéciale des actionnaires, les actionnaires présents détenaient eux-mêmes toutes le capital-actions émis de la compagnie; et les actionnaires qui votèrent en faveur dudit règlement détenaient eux-mêmes tout le capital-actions émis et réparti de la compagnie.Et nous avons signé à Montréal, ce 29e jour d'août 1958.lie Président, RUBEN KLUGER.(Sceau) Le Secrétaire, 48830 P.RABINOVITCH.(P.G.3184-53) North American Management Corporation Règlement N° XXIII Que le règlement suivant soit et il est, par les présentes, décrété comme le règlement N° XXIII des règlements de \"North American Management Corporation.' Règlement N° XXIII Nombre de directeurs 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, diminué de neuf (9) à cinq (5) de manière que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de cinq (5) directeurs.2° Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie, incompatibles à icelui' sont, par les présentes, amendés pour se conformer aux dispositions de ce règlement.Vraie copie certifiée du règlement N° XXIII de \"North American Management Corporation\" (A.G.13627-57) Dreamwear Ltd.By-law No.22 \"Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of \"Dreamwear Ltd.\", as follows: 1.The number of directors of the company be and the same are hereby increased from three to four so that the board of directors of the company shall hereafter be composed of four directors.2.Four directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.\" We, the undersigned, Rubin Kluger and Dr.Plrineas Rabinovitch, respectively president and secretary of \"Dreamwear Ltd.\", do hereby certify under the corporate seal of the company that the foregoing is a true and correct copy of by-law No.22 of the company regularly adopted by the board of directors of the said company at a meeting duly and regularly called ami held at the office of the company on the 29th day of August.1958, the whole in the manner and form by law required; and that at a special general meeting of the shareholders of the company duly and regularly called and held at the office of the company on the 29th of August, 1958, the said by-law No.22 was didy ratified, confirmed and approval for all legal purposes; and that at at the said special general meeting of shareholders, the shareholders present held themselves all the issued capital stock of the company; and that the shareholders who voted in favour of the said by-law held themselves all the issued and allotted capital stock of the company.And we have signed at Montreal, this 29th day of August, 1958.RUBEN KLUGER, President.(Seal) P.RABINOVITCH, 48830-o Secretary.(A.G.3184-53) North American Management Corporation* By-law No.XXIII That the following be and it is hereby enacted as by-law No.XXIII of the by-laws of \"North American Management Corporation\".By-law No.XXIII Number of directors 1.The number of directors of the company be ami it is hereby reduced from nine (9) to five (5) so that the board of directors of the company shall hereafter be composée! of five (5) directors.2.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent with this by-law are hereby amended to confirm with the provisions of this by-law.Certified a true copy of by-law No.XXIII of \"North American Management Corporation\" 3562 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958, Tome 90, N° 42 dûment décrété à une assemblée du bureau de direction de la compagnie tenue le 13e jour d'août 1958, et sanctionné et confirmé à une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie tenue le 25e jour d'août 1958 par le vote unanime de tous les actionnaires présents en personne ou par procuration à ladite assemblée.(Sceau) Le Secrétaire, 48831 J.A.HAYMAN.(P.G.9508-49) Matapedia Holding Corporation Règlement concernant l'augmentation du nombre des directeurs de trois à cinq: II est proposé par Camille Lacroix et unanimement résolu que le paragraphe 3 du règlement N° 1 des règlements généraux «le la compagnie, soit amendé pour augmenter le nombre des directeurs à cinq au lieu de trois, tel qu'approuvé à une assemblée des directeurs tenue le même jour, et qui devra se lire comme suit: \"Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau «le direction composé de cinq membres, dont trois constitueront le quorum requis pour toute assemblée des directeurs.\" Certifié vraie copie ce 17 juin 1958.Le Secrétaire, 48833-o YVETTE LACROIX.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Magasin Co-op de Québec\", en date du 27 septembre 1958, dont le siège social est situé à La Petite-Rivière, comté de Saint-Sauveur, district judiciaire de Québec, et que ce document a été déposé dans les archives «lu Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le trois octobre 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48834-0 JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Syndicat de Chantiers Coopératifs d'Anse-St-Jean\", en date du 21 septembre 1958, dont le siège social est situé à l'Anse-St-Jean, comté de Chicoutimi, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le trente septembre 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48837-0 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.18352-53) L.H.Ouimet & Cie Limitée Copie du règlement numéro 39 adopté par les directeurs de \"L.H.Ouimet & Cie Limitée\", lors d'une assemblée tenue le 8 août 1957 et ratifié par les actionnaires lors d'urte assemblée tenue le même jour.Règlement 89 \"Il est unanimement résolu de diminuer le nombre des directeurs de la compagnie \"L.H.Ouimet & Cie Limitée\", de quatre à trois.\" Le Secrétaire, 48838-0 R.OUIMET.duly enacted at a meeting of the board of directors of the company held on the 13th day of August, 1958, and sanctioned and confirmed at a special general meeting of the shareholders of the company held on the 25th day of August, 1958, by the unanimous vote of all the shareholders present in person or by proxy at such meeting.(Seal) J.A.HAYMAN, 4883l-o Secretary.(A.G.9508-49) Matapedia Holding Corporation By-law concerning an increase in the number of directors from three to five: It was moved by Camille Lacroix and unanimously resolved that paragraph 3 of by-law No.1 of the company's general by-laws be amended in order that the number of directors be increased to five in lieu of three, as confirmed at a meeting of directors held the same day, and which should read as follows: \"The affairs of the company shall be managed by a board of directors composed of five members, three of whom shall form the quorum required at any meeting of directors.\" Certified true copy, this June 17, 1958.YVETTE LACROIX, 48833 Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Magasin Co-op de Québec\", under date September 27, 1958, whereof the head office is at La Petite-Rivière, county of Saint-Sauvcur, judicial district of Quebec, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this third day of October, 1958.JEAN BRUCHÉSI, 48834 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat de Chantiers Coopératifs d'Anse-St-Jean\", under date of September 21, 1958, whereof the head office is at Anse-St-Jean, County of Chicoutimi, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this thirtieth day of September, 1958.JEAN BRUCHÉSI, 48837 Under Secretary of the Province.(A.G.18352-53) L.H.Ouimet & Cie Limitée Copy of By-law number 39 adopted by the Directors of \"L.H.Ouimet & Cie Limitée\", et a meeting held August 8, 1957 and confirmed by the shareholders at a meeting held the same day.By-law 89 \"It is unanimously resolved to decrease the number of Directors of the Company \"L.H.Ouimet & Cie Ltée\", from four to three.\" R.OUIMET, 48838 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1968, Vol.90, No.m 3563 Bills, Assemblée législative Avis de L'Assemblée Législative Concernant les bills privés qui seront présentés pendant la prochaine session.Aux ternies du règlement, les bills privés devront être déposés avant le 29 actobre 1958 et présentés avant le 10 décembre 1958, les pétitions introductives de bills privés devront être présentées avant le 29 novembre 1958 et reçues avant le 4 décembre 1958, et les rapports de comités élus chargés de l'examen des bills privés devront être reçus avant le 24 décembre 1958.Québec, 3 septembre 1958.Le Greffier de l'Assemblée législative, ANTOINE LEMIEUX.48527-36-1 l-o Chartes \u2014 Abandon de Bills, Legislative Assembly Notice of Legislative Assembly Concerning provate bills which shall be introduced during the coming Session.According to standing orders, private bills shall be deposited before October 29th, 1958 and introduced before December 10th, 1958, petitions for private bills shall be presented prior to November 29th, 1958 and received prior to December 4th, 1958, and reports from elected committees charged with the examining of private bills must be received before December 24th, 1958.Quebec, September 3, 1958.ANTOINE LEMIEUX, Clerk of the Legislative Assembly.48527-36-11 Charters \u2014 Surrender of Bishop Asphalt Papers Limited AVIS En vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Quél>cc, telle qu'amendée, \"Bishop Asphalt Papers Limited\" donne avis par les présentes, qu'elle fera application à l'honorable Procureur Général de Québec pour qu'il accepte l'abandon de sa charte et en ordonne son annulation, et fixe une date à compter de laquelle elle sera dissoute.Montréal, P.Q., le 3ème jour d'Octobre, 1958.Le Secrétaire, 48812-o A.N.RAYBOULD.AVIS Conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec, la compagnie \"Les Mines d'Huile et Pétrole Tremblay-Joubert Compagnie Limitée\", donne par les présentes, avis qu'elle demandera la permission d'abandonner sa charte et la fixation d'une date à compter de laquelle la compagnie sera dissoute.Montréal, le 8 octobre 1958.Les Mines d'Huile et Pétrole Tremblay-Joubert Compagnie Limitée, Par le Secrétaire, 48813-o ARTHUR LARENTE.Avis est, par les présentes, donné en vertu de Loi des compagnies de Québec, que \"Air Tacker Co.Inc.\" s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 9 octobre 1958.Le Procureur de la requérante, IRWIN A.FRANKEL.4 est, rue Notre-Dame, Montréal, Que.48819 Bishop Asphalt Papers Limited NOTICE Under the provisions of the Quebec Companies' Act, as amended, \"Bishop Asphalt Papers Limited\" hereby gives notice that it will make application to the Honourable the Attorney-General of Quebec for acceptance of the surrender of its charter and to direct its cancellation and fix a date upon and from which it shall he dissolved.\" Montreal, P.Q., October 3rd, 1958.A.N.RAYBOULD.48S12-o Secretary.NOTICE In accordance with the provisions of the Quebec Companies' Act, the company \"Les Mines d'Huile et Pétrole Tremblay-Joubert Compagnie Limitée\", hereby gives notice that it will apply for leave to surrender its charter and the setting of date as from which the company shall be dissolved.Montreal, October 8.1958.Les Mines d'Huile et Pétrole Tremblay-Joubert Compagnie Limitée, Per: ARTHUR LARENTE.48813 Secretary.Notice is hereby given, in accordance with the Quebec Companies' Act, that \"Air Tacker Co Inc.\", will apply to the Attorney-General for the Province of Quebec for leave to surrender its charter.Montreal, October 9, 1958.IRWIN A.FRANKEL, Attorney for Petitioner.4 Notre-Dame St.East, Montreal, Que.48819-o Compagnies autorisées à faire Companies Licensed to do des affaires Business (Sec.P.469-58) (P.Sec.469-58) Avis est, par les présentes, donné que \"Brown Notice is hereby given that \"Brown & Root & Root Ltd.\", une compagnie à fonds social Ltd.\", an extra-provincial corporation incor- 3564 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958, Tome 90, N° 1& étrangère constituée en vertu, d'un dépôt de mémoire et articles de la compagnie, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de la province de l'Alberta, a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies a fonds social étrangères, S.R.Q., 1941, chapitre 279.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province est à chambre 303, 901 carré Victoria, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures exercées contre elle, est M.Albert Bronson Culver, avocat, de ladite cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 14e jour d'octobre 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48799 JEAN BRUCHÉSI.(Sec.P.472-58) Avis est, par les présentes, donné que \"The John L.Klug Corporation\", une compagnie à fonds social étrangères constituée en vertu de \"Stock Corporation Law\" de l'état de New York, a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères, S.R.Q., 1941, chapitre 279.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province est à chambre 300 - 455 ouest, rue Craig en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures exercées contre elle, est M.W.H.Laidley, à l'adresse donnée ci-dessus.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 14e jour d'octobre 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48799 JEAN BRUCHÉSI.Demandes à la Législature porated in virtue of the filing of Memorandum and Articles of Association pursuant to the provisions of the Companies Act of the Province of Alberta, has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, R.S.Q., 1941, chapter 279.The principal office of the said company in the Province is to be established at room 303, 901 Victoria Square, in the city and judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.Albert Bronson Culver, advocate, of the said city of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of October, 1958.JEAN BRUCHÉSI, 48799-o Under Secretary of the Province.(P.Sec.472-58) ¦ Notice is hereby given that \"The John L.Klug Corporation\", an extra-provincial corporation incorporated in virtue of the stock corporation law of the State of New York, has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, R.S.Q., 1941, chapter 279N.The principal office of the said company in the Province is to be established at Room 300 -455 Craig Street, West, in the city and judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.W.H.Laidley, of the above given address.Given at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of October, 1958.JEAN BRUCHÉSI, 48799-o Under Secretary of the Province.Applications to Legislature Canada \u2014 Province de Québec District de Rimouski Avis est par les présentes donné que La corporation du village de Price, comté de Matane, s'adressera à la Législature de Québec à sa prochaine session pour demander l'adoption d'un bill aux fins suivantes: 1.Imposer une taxe de vente de 2% (deux pour cent) sur les ventes en détail dans les limites de son territoire.2.Pour toutes autres fins.Mont-Joli, le 18 septembre 1958.Les Procureurs de la pétitionnaire, 48679-39-4-o RHEAULT & CARLE.ÂVÏS Avis est par les présentes donné que John Nemeth, de la cité et du district de Montréal, resident actuellement dans la cité d'Ottawa, province d'Ontario, s'adressera à l'Assemblée législative de Québec, lors de sa prochaine session, afin d'obtenir une loi autorisant le Barreau de la province de Québec à admettre John Nemeth à l'étude et à la pratique du droit dans la province de Québec.Montréal, 16 septembre 1958.Le Procureur du requérant, 48680-39-4-o GRAHAM GOULD, C.R.Canada \u2014 Province Of Quebec District of Rimouski Notice is hereby given that The corporation of the village of Price, county of Matane, will apply to the Quebec Legislature at its next session, for the adoption of a bill for the following purposes: .1.To impose a sales tax of 2% (two per cent) on retail sales, within the limits of its territory.2.For any other purposes.Mont-Joli, September 18, 1958.RHEAULT & CARLE, 48679-39-4 Attorneys for the petitioner.NOTICE Notice is hereby given that John Nemeth of the city and district of Montreal, in the Province of Quebec, presently residing at the city of Ottawa in the Province of Ontario, will apply to the Legislative Assembly of the Province of Quebec, at its next session, for an act to authorize the Bar'of the Province of Quebec to admit John Nemeth to the study and practice of law in the Province of Quebec.Montreal, September 16, 1958.GRAHAM GOULD, Q.C., 48680-39-4-o Solicitor for Petitioner. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1958, Vol.90, No.42 3565 Canada \u2014 Province de Québec District de Hull AVIS La corporation municipale de Portland Est et La commission scolaire de' Notre-Dame de la Salette, est par les présentes donné: Que La corporation municipale de Portland Est et La commission scolaire de Notre-Dame de la Salette, s'adresseront à la Législature de la province de Québec, à la prochaine session pour faire fixer les taxes municipales et scolaires de la compagnie de \"James Maclaren, Co.Ltd.\", pour une période de dix (10) ans.Donné à Notre-Dame de la Salette, ce 5 septembre 1958.(Signé) Le Secrétaire-trésorier, DIOMÊDÊ BISSON.Le maire, HECTOR LAUZON.Le Président, AIMÉ BRAZEAU.J.JACQUES BOILEAU, 48681-39-4-0 LIONEL MOUGEOT.Avis public est.par les présentes, donné que Dame Maria de Rutrecht, épouse contractuelle-ment séparée de biens de William Wenman.gérant des ventes, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa prochaine session, pour demander l'adoption d'une loi spéciale validant son titre d'acquisition d'un immeuble situé au numéro civique 1825 ouest, rue Dorchester, à Montréal, et qu'elle a acheté de la Succession de feu Henri B.Rainville.Montréal, le 26 septembre 1958.Le Procureur de Dame Maria de Rutrecht, 48727-40-4-o ALBERT LANGEVIN.Avis est par les présentes donné que les Commissaires d'école de la cité de Jonquière, s'adresseront à la Législature déjà province de Québec, à sa prochaine session, pour l'adoption d'une loi, afin d'autoriser une indemnité aux commissaires et au président, pour leurs frais de déplacements, de représentation et autres dépenses.Québec, le 2 octobre\" 1958.Le Procureur des Commissaires d'école de la cité de Jonquière.48762-41-4-0 RENÉ BOUDREAULT.Avis est par les présentes donné que les commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de Plessisvillcî clans le comté de Mégantic, s'adresseront à la prochaire session de la Législature de Québec pour obtenir le pouvoir de payer au président et aux commissaires d'écoles une rémunération; pour obtenir le pouvoir d'obliger les maîtres d écoles à enseigner dans une classe ou école indifféremment à une autre; pour obtenir que le taux d'intérêt sur les arrérages de taxes soit haussé de 6% au lieu de 5% qu'il était auparavant et pour d'autres fins.Plcssisville, ce 24èmc jour de septembre 1958.Le Procureur de la requérante, 48763-41-4-0 JEAN L.DUTIL.Avis est par les présentes donné que \"The University of Bishop's College\" s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa prochaine session, pour demander l'adoption d'une loi changeant son nom à \"Bishop's University\".Sherbrooke, le 6 octobre 1958.Les Procureurs de la requérante, COMMON, HOWARD, CATE, OGILVY, BISHOP, COPE, 48764-41-4-o PORTEOUS & HANSARD.Canada \u2014 Province of Quebec District of Hull NOTICE The municipal corporation of Portland East and The school commission of Notre-Dame de la Salette, is hereby given that The municipal corporation of Portland East and The school commission of Notre-Dame de la Salette, will appear before the Législature of Province of Quebec at its next session to ask a fixation of the amount of municipal and school taxes of the \"James Maclaren, Co.Ltd.\", for a period of ten (10) years.Signed at Portland East, this 5th day of September, 1958.(Signed) DIOMFDÊ BISSON, Secretary-Treasurer.HECTOR LAUZON, Mayor.AIMÉ BRAZEAU, President.J.JACQUES BOILEAU.48681-39-4-0 LIONEL MOUGEOT.Public notice is hereby given that Dame Maria de Rutrecht, wife separate as to property by marriage contract of William Wenman, sales manager, of Montreal, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, for the adoption of a special law declaring valid her title of acquisition of an immoveable situated at civic number 1825, Dorchester Street West, in Montreal, which was acquired from the Estate of the late Henri B.Rainville.Montreal, September 26th, 1958.ALBERT LANGEVIN, Attorney for 48727-40-4-o Mrs.Maria de Rutrecht.Notice is hereby given that The School Commissioners for the city of Jonquière will make application to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, for the adoption of a law to autorize an indemnity to the commissioners and the president for their travelling, entertainment and other expenses.Quebec, October 2nd, 1958.RENÉ BOUDREAULT, Sollicitor for the School Commissioners 48762-41-4-o for the city of Jonquière.Notice is hereby given that the school commissioners for the municipality of the town of Plessisvillc, in the county of' Mégantic, will apply to the next session of the Quebec Legislature to obtain the power to pay to the president and the school commissioners, a remuneration; to obtain the power to oblige school masters to teach in either a class >or a school, indifferently, one or the other; to obtain that the rate of interest on tax arrears be raised to 6% instead of 5% that it has been heretofore and for other purposes.Plcssisville, this 24th day of September, 195S.JEAN L.DUTIL, 48763-41-4-0 Attorney for the petitioner.Notice is hereby given that \"The University of Bishop's College\" will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its next session for the passing of an Act changing its name to \"Bishop's University\".Sherbrooke, October 6th, 1958.COMMON, HOWARD, CATE.OGILVY, BISHOP, COPE, PORTEOUS & HANSARD, 48764-4 l-o Attorneys for the petitioner. 35(H) GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958, Tome 90, N° 42 Le soussigné donne avis qu'il présentera, à la prochaine session de la Législature de Québec, un projet de loi pour admettre Hugo Bartoli, d'Ottawa, à l'étude et à l'exercice de la profession d'avocat dans la province de Québec.48765-41-4-o LOUIS DORION, avocat.Avis de la présentation d'un projet de loi amendant la charte de la ville de ' Ste-Thérèse Avis est par la présente donné, que la ville de Ste-Thérèse, s'adressera à la législature de Québec à sa prochaine session, pour demander l'adoption d'une loi aux fins suivantes: 1° Pour amender sa charte dans le but d'annexer certains territoires contigues à la ville de Ste-Thérèse, dans le comté de Terrebonne; 2° Pour amender sa charte dans le but d'obtenir certains pouvoirs additionnels favorisant l'expansion de son système d'égout et d'aqueduc, la construction de trottoirs et de rues et autres pouvoirs; 3° Pour amender sa charte dans le but de constituer la ville de Ste-Thérèse, en cité de Ste-Thérèse.Ste-Thérèse, le 7 octobre 1958.Les Procureurs de la requérante, ROGER LAJEUNESSE 48776-41-4-0 et ANDRÉ FAUTEUX.La cité Saint-Jean Avis public est, par la présente donné que la cité Saint-Jean, présentera à la Législature de la province de Québec, à la prochaine session, une pétition dans le but d obtenir certaines modifications à sa charte et certains pouvoirs complémentaires et particulièrement dans le but d'obtenir le pouvoir de diviser le territoire de la cité en trois quartiers, de rendre la représentation par quartiers, au sein du conseil, de changer la date des élections municipales, de fixer les heures d'ouverture et de fermeture du bureau du secrétaire-trésorier de valider le règlement créant la Cour municipale et les actes de cette dernière depuis 1952, de statuer sur la procédure des délibérations du conseil, de proportionner la taxe de locataire au temps d'occupation et de changer la cotisation des lots faisant face à deux rues.Saint-Jean, 7 octobre 1958.La cité Saint-Jean, Par le Secrétaire-trésorier, 48797-41-4-0 J.-WTLFRID BOUTIN.Avis est par les présentes donné que Les commissaires d'écoles catholiques de la cité de Sorel, dans le comté de Richelieu, s'adresseront à l'Assemblée législative de la province de Québec, à sa prochaine session, pour qu'une loi soit adoptée en vue de l'établissement et la perception d'un impôt spécial de deux pour cent (2%) pour fins éducationnelles et scolaires.Sorel, le 6 octobre 1958.Le Président, PAUL-A.PÊLOQUTN.Le Secrétaire-trésorier, 48798-0 THÉODORE BARDD3R.In re: Dame Colette Perroux-Maranda Avis est par les présentes donné que Collette Perroux-Maranda, étudiante, citoyenne canadienne de la cité de Montréal, s'adressera à la The undersigned gives notice that he will introduce a private bill at the next session of the Legislature of Quebec, in order that Hugo Bartoli, of Ottawa, be admitted to the study and practive of the profession of advocate in the Province of Quebec.48765-41-4-0 LOUIS DORION, Advocate.Notice of the request for the adoption or a bill amending the charter of the town of Ste Thérèse Notice is hereby given that the town of Sainte-Thérèse, shall apply to the Quebec Legislature, at its next session to request the adoption of a bill for the following purposes: 1° To amend its charter with a view to annex some territory contiguous to the present boundaries of the town of Sainte-Thérèse, in the county of Terrebonne; 2.To amend this charter in order to obtain certain additional powers for the purpose of expanding its aqueduc and water system, constructing Fonds and sidewalks and other specified powers; 3.To amend its charter in order to make the town of Sainte-Thérèse into the city of Sainte-Thérèse.Sainte-Thérèse, the 7th of October 1958.ROGER LAJEUNESSE and ANDRE FAUTEUX, 48776-41-4-o Attorneys for the Petitioner.Saint-John's City Public notice is hereby given that Saint-John's City will present to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, a petition for the purpose of obtaining certain modifications to its charter and certain complementary powers and especially for the purpose of obtaining the power to divide the territory of the city into three wards, to have ward representation in the council, the change the date of the municipal elections, to fix opening and closing hours for the secretary-treasurer's office, to validate by-law creating the Municipal Court and the acts of the latter since 1952, to enact on the procedure and deliberations of the council, to tax tenants proportionately to the time of occupation and to change the assessment of lots which face two streets.Saint-John's, October 7, 1958.Saint-John's City By J.-WLLFRID BOUTIN, 48797-41-4 Secretary-Treasurer.Notice is hereby given that The commissioners of the Catholic school board of the city of Sorel shall make an application to the Legislative Assembly of Quebec, at its next session, to vote a law for the establishment and collection of a special tax of two per cent (2%) for educational and school matters purposes.Sorel, October 6th, 1958.PAUL-A.PÉLOQUIN, Chairman.THÉODORE BARDIER, 48798-o Secretary-Treasurer.In re: Mrs.Colette Perroux-Maranda Notice is hereby given that Collette Perroux-Maranda, student, Canadian Citizen of the city of Montreal, will apply to the Legislature of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1958, Vol.90, No.42 3567 législature de la Province de Québec, à la prochaine session, dûment autorisée à cet effet par le bureau provincial de la chirurgie Dentaire, afin que le Collège des chirurgiens-Dentistes de la province de Québec soit autorisé à lui accorder une licence pour l'exercice de la chirurgie dentaire, à condition toutefois qu'elle passe devant les représentants du Collège, l'examen final, tel qu'exigé des candidats de la province.Montréal, le 3ème jour d'octobre 1958.Les Procureurs de la pétitionnaire, NANTEL, MERCURE & 48826-42-4-0 SURPRENANT.Province of Quebec at its next session, duly authorized by the Board of Dental Surgery, in order to authorize the Provincial Board of Dental Surgery to grant her licence when she shall have passed the required examinations before the Provincial Board of Dental Surgery examinators.Montreal, this 3rd day of October 1958.NANTEL, MERCURE & SURPRENANT, 48826-42-4-o Attorneys for the Petitioner.Avis est par les présentes donné que les commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de Rimouski, s'adresseront à la Législature de Québec, à sa prochaine session, pour l'adoption d'une loi les autorisant à imposer une taxe d'éducation de 2% sur les ventes au détail et autres fins.Rimouski, le 8 octobre 1958.¦ Les Procureurs des pétitionnaires, 48827-42-4-0 GAGNON & GAGNON.Notice is hereby given that the school commissioners for the municipality of the town of Rimouski, will petition the Legislature of Quebec, at its coming session, for the passing of a law authorizing them to impose an education tax of 2% on retail sales and other purposes.Rimouski, October 8th, 1958.GAGNON & GAGNON.48827-42-4-o Attornies for petitionners.Le soussigné donne avis qu'il présentera, à la prochaine session de la Législature de Québec, un projet de loi pour autoriser le Barreau de la province de Québec à accorder aux études de Droit faites par Maximilien Polak de Montréal, à l'Université de ' Leyden, Hollande, l'équivalence de la première année du cours régulier de Droit de l'Université de Montréal.Le Procureur du pétitionnaire, 48828-42-4-0 LOUIS DORION, avocat.The undersigned gives notice that he will present, at the next session of the Quebec Legislature, a project of law to authorize the Provincial Bar to grant to the study of law made by Maximilien Polak of Montreal, at the University of Leyden, Holland, the equivalent of the first year in the regular Law Course of the Montreal University.LOUIS DORION.advocate, 48828-42-4 Attorney for the petitioner.Ville de Coukville Avis est, par les présentes, donné, que la ville de Courville, dans le comté de Québec, s'adressera à la Législature de la province de Québec, lors de la prochaine session, pour obtenir un amendement sa charte, aux fins suivantes; Établissement de centres de loisirs; Pour réglementer l'usage des fusées, pétards, etc.Pour déterminer le nombre maximum de taxis dans la municipalité, et réglementer leur usage; Pour autoriser à signer toute convention de services d'utilité publique, avec toute communauté religieuse; Pour autoriser la prolongation des égouts collecteurs, dans toutes municipalités voisines de la ville de Courville; Pour pouvoir emprunter annuellement, durant une période de trois ans, une somme n'excédant pas 850,000.00; *» Pour payer une pension au greffier, après vingt ans t C de la resubdivision du lot N° 1144 (1144-C-l) des plan et livre «le renvoi officiels du quartier St-Antoinc, «lans la cité de Montréal; c) valider la transmission par décès des immeubles dépendant de la succession; Et pour toutes autres fins.Montréal, ce 10 octobre 1958.Avocats des requérants, es-qualité, BEAULIEU, BEAULIEU & 48842-42-4-o CASGRAIN.Notice is hereby given that the Quebec Catholic School Commission will apply to the Quebec Legislature, at its next session, for the adoption of a bill for the following purposes: 1.Increase its borrowing powers; 2.Authorize the hiring of teachers by the day; 3.Cancel the appointment of and replace school-mistresses in the event of their marriage.Quebec, October 15, 1958.JACQUES DROUIN, 48840-42-4 Attorney for petitioner.Public notice is hereby given that The school commissioners for the school municipality of the town of Joliette, county of Joliette, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, for the adoption of an act permitting to the said school commissioners, to increase from 1 to 2% the rate of the education tax which they already collect.an«l for other purposes.Joliette, October 10th.1958.J.-ARTHUR LÉPINE, 4S841-42-4-o Attorney for petitioners.In re: Masson Estate Public notice is hereby given that: Leon Masson, administrator, of the city and district of Montreal: Alphonse Milette, administrator, of the city of Terrebonne, district of Terrebonne; Charles de Lotbinière Harwood, manager, of the city of Westmount, «listrict of Montreal; .Jaque Masson, administrator, of the city of Montreal, «listrict of Montreal; All four being the sole testamentary executors and trustees now in office of the estate of the late Honourable Joseph Masson in his lifetime merchant of the sai«l city of Montreal, and all four acting in their quality of testamentary executors and trustees of the said estate; Shall apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, in order to obtain a special law, for the following purposes: a) to postpone the partition of the property of the estate and to maintain in force during the entire lenght of the postponement, all the rights, powers ami privileges of the said testamentary executors and trustees; 6) to determine more exactly, extend ami clarify the powers, attributions and functions of the said testamentary executors ami trustees, of the majority of them, ami of the survivors in case of death of one or more of the said testamentary executors and trustees; c) to ratify and validate the appointments of the said testamentary executors and trustees now in function ami to clarify the proce«lure to be followed for future appointments; d) to ratify, confirm and validate the sale by licitation to the estate of the lot of land known as lot No.1 of the subdivision of lot C of the resubdivision of lot 1141 (1144-C-l) as per the official plan and book of reference of St.Antoine ward, in the city of Montreal ; e)-to validate the transmission by death of the immoveables held by the estate; And for other purposes.Montreal, October 10, 1958.BEAULIEU, BEAULIEU & CASGRAIN, 48842-42-4-o Attorneys for petitioners, es-qual. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1968, Vol.90, No.& 3569 - Avis public est par les présentes donné que la ville de Nicolet s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa prochaine session, pour obtenir l'adoption d'une loi l'autorisant: 1° Amender l'article 14 de la loi 1 George V, 1910, chapitre 57; 2° Amender l'article 11 de la loi 4-5 Elizabeth II, chapitre 99, de façon à ce que les pouvoirs accordés par cet article soient continués pour cinq ans; 3 Que la ville soit autorisée à emprunter $50,000.00 pour l'établissement d'industries; 4* Annexer à son territoire une partie du territoire de La municipalité de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, savoir, les lots 361, 362, 363, 364 et 365; 5° Pour toutes autres fins.Nicolet, le 14 octobre 1958.Le Procureur de la pétitionnaire, 48843-42-4-o ARMAND PROULX.Avis public est par les présentes donné que la cité de Sherbrooke s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa prochaine session pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, lu loi 1 George VI, chapitre 105, aux fins suivantes: 1° Amender l'article 3 de la loi 3-4 Elizabeth II, chapitre 70, pour le changement de la date de préparation de la liste des électeurs.2° Amender l'article 1 de la loi 4-5 Elizabeth II, chapitre -71, pour concordance à l'article précédent.3° Amender la loi 1 George VI, chapitre 105, aux fins d'autoriser la cité à installer des clôtures-à neige dans tout endroit nécessaire.4° Amender la loi 1 George VI, chapitre 105, pour permettre aux autorités civiles la fermeture de certaines rues au printemps.5° Amender la loi 1 George VI, chapitre 105, pour permettre aux autorités civiles de détourner le trafic lourd selon qu'elles le jugeront opportun.6° Que la cité soit autorisée à emprunter chaque année, $300,000.00 pour une période de 10 ans, pour l'homologation et l'achat des terrains nécessaires aux voies de circulation, ponts, viaducs, etc.Et autres demandes.Sherbrooke, 6 octobre 1958.Le Procureur de la requérante, 48844-42-4-o ALBERT RIVARD.Avis public est donné que Les commissaires d'écoles pour la ville de Windsor-Mills et Les commissaires d'écoles pour la ville d'East-Angus feront à la Législature de la province de Québec, à sa prochaine session une demande conjointe pour avoir la permission d'imposer dans leurs territoires respectifs une taxe d'éducation de 2%.Asbestos, le 14 octobre 1958.Le Procureur des requérants, 48845-42-4-o (Signé) LOUIS LANGLAIS.Département de l'Agriculture Public notice is hereby given that the town of Nicolet will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, to obtain the adoption of an act authorizing it to: 1.Amend section 14 of act 1 George V, 1910, chapter 57; 2.Amend section 11 of act 4-5 Elizabeth H, chapter 99, in order that powers granted by said section be extended for a period five years; 3.That the town be authorized to borrow $50,000.00 for the establishment of industries; 4.Annex to its territory, a part of the territory of The municipality of the parish of Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, that is to say, lots 361, 362, 363, 364 and 365; 5.For all other purposes.Nicolet, October 14, 1958.ARMAND PROULX, 48843-42-4 Attorney for petitioner.Public notice is hereby given that the city of Sherbrooke will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, for the passing of an act amending its charter, the act 1 George VI, chapter 105, for the following purposes: 1.To amend act 3-4 Elizabeth II, chapter 70, article 3 in order to change the date for the filing of the electors list.2.To amend act 4-5 Elizabeth II, chapter 71, article 1 in connection with the above article.3.To amend act 1 George VI, chapter 105, granting permission to the city authorities to install snow fences wherever they may be necessary.4.To amend act 1 George VI, chapter 105, granting permission to the city authorities to close any street in spring time.5.To amend act 1 George VI, chapter 105, granting permission to the city authorities to divert heavy trafic as they shall find advisable.6.For the authorization to borrow yearly, for the next 10 years, $300,000.00 for the purpose of homologation and purchase of lands necessitated for the opening of streets, bridges, viaducts, etc.And other purposes.Sherbrooke, October 6th, 1958.ALBERT RIVARD, 48844-42-4-o Attorney for the petitioner.Public notice is hereby given that The school commissioners for the town of Windsor-Mills and The school commissioners for the town of East-Angus will make a joint request to the Quebec Legislature, at its next session, to obtain permission to impose in their respective territories a 2% education tax.Asbestos, October 14, 1958.- (Signed) LOUIS LANGLAIS, 48845-42-4-0 Attorney for the petitioners.Department of Agriculture Avis est par le présent donné que, du consentement du bureau de direction de la \"Montreal Milk Producers' Co-operative Agricultural Association\", le nom de cette coopérative agricole est changé en celui de \"Montreal Milk Producers' Co-operative \u2014 Coopérative des Pro- Notice is hereby given by these presents that, with the consent of the Board of Directors of the \"Montreal Milk Producers' Co-operative Agricultural Association\", the name of this agricultural co-operative is changed into that of \"Montreal Milk Producers' Co-operative \u2014 3570 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958, Tome 90, N° & ducteurs de Lait de Montréal\", conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi des Sociétés Coopératives Agricoles (S.R.Q.1941, ch.120).Le siège social de la coopérative est à Montréal.Le présent avis remplace l'avis paru dans la Gazette Officielle de Québec du 6 septembre 1958, page 3031., Fait ce neuvième jour d'octobre 1958.Le Ministre de l'Agriculture, 48836-0 LAURENT BARRÉ.Coopérative des Producteurs de Lait de Montréal\", pursuant to the provisions of section 9 of the Cooperative Agricultural Associations (R.S.Q.1941, chap.120).The head office of the co-operative is in Montreal.The present notice replaces the notice which appeared in the Quebec Official Gazette of September 6, 1958, page 3031.Given this ninth day of October, 1958.LAURENT BARRÉ, 48836 f Minister of Agriculture.Département de l'Instruction Publique N?59-58.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 2 octobre 1958, d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de St-Jacques, dans le comté de Deux-Montagnes, à celui de la municipalité scolaire de St-Canut, dans le même comté.Ce changement prendra effet au 1er juillet 1959.Québec, le 14 octobre 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 48832-0 O.J.DÊSAULNIERS.N° 621-58.II a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 2 octobre 1958, de changer le nom de la municipalité scolaire de St-Benoit Labre, dans le comté de Matapédia, en celui de la municipalité scolaire de la paroisse d'Amqui, dans le comté de Matapédia.Ce changement prendra effet huit jours après la publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec.Québec, le 14 octobre 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 48832-o O.J.DÊSAULNIERS.Department of Education No.59-58.His Honour, the Lieutenant-Governor in council, by order in council, dated October 2, 1958, has been pleased to annex the present territory of the school municipality of St-Jacques in the county of Two-Mountains into that of the school municipality of St-Canut, in the same county.This change will take effect on July 1st, 1959.Quebec, October 14, 1958.O.J.DÊSAULNIERS, 48824 Superintendent of Education.No.621-58.His Honour, tlic Lieutenatn-Governor in council, by order in council, dated October 2,1958, has been pleased to change the name of the school municipality of St-Benoit-Labre, in the county of Matapédia, into that of the school municipality of the parish of Amqui, in the county of Matapédia.This change of name will take effect eight days after the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Quebec, October 14, 1958.O.J.DÊSAULNIERS, 48832 Superintendent of Education.N° 720-58.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 2 octobre 1958, de changer le nom de la municipalité scolaire de Notre-Dame-des-Bois de Chesham, dans le comté de Frontenac, en celui de la municipalité scolaire de Notre-Dame-des-Bois, dans le comté de Frontenac.Ce changement prendra effet huit jours après la publication de cet avis dans la Gazette officielle de Qtt&l)CCt Québec, le 14 octobre 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 48832-0 O.J.DÊSAULNIERS.No.720-58.His Honour, the Lieutenant-Governor in council, by order in council, dated October 2, 1958, has been pleased to change the name of the school municipality of Notre-Dame-des-Bois de Chesham, in the county of Frontenac, into that of the School Municipality of Notre-Dame-des-Bois, in the county of Frontenac.This change of name wil take effect eight days after the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Quebec, October 14, 1958.O.J.DÊSAULNIERS, 48832 Superintendent of Education.N° 1272-55.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 2 octobre 1958, de changer le nom de la municipalité scolaire de ville St-Martin, dans le comté de Laval, en celui de la municipalité scolaire de St-Martin, dans le même comté.Ce changement prendra effet huit jours après la publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec.Québec, le 14 octobre 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 48832-o O.J.DÊSAULNIERS.No.1272-55.His Honour, the Lieutenant-Governor in council, by Order in council, dated October 2, 1958, has been pleased to change the name of the school municipality of ville St-Martin, in the county of Laval, into that of the school municipality of St-Martin, in the same county.This change of name will take effect eight days after the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Quebec, October 14, 1958.O.J.DÊSAULNIERS, 48832 Superintendent of Education. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1968, Vol.90, No.Ifi 3571 Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Beauport (municipalité de Beauport-Ouest), division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 560-13 et 565-25 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 7 octobre 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 48801-o A VILA BÊDARD.Cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame de L'Assomption de Repentigny (municipalité de Repentigny), division d'enregistrement de L'Assomption.Avis est par la présente donné que les lots 119-3 à 119-25 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 2 octobre 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 48801-o AVILA BÉDARD.Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Foye (municipalité de cité de Ste-Foy), division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 181-21-A, 181-21-B, 181-21-C, 181-21 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 7 octobre 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 48801-o AVILA BÊDARD.Cadastre officiel du village de Windsor Mills (municipalité de ville de Windsor) division d'enregistrement de Richmond.Avis est par la présente donné que les lots 465-11, 465-12, 519-1, 519-2, 528-A-l à 528-A-10 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 22 septembre 1958.Le Département des Terres et Forêts, « Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 48801-o AVILA BÊDARD.Cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame de St-Hyacinthe (municipalité de cité de St-Hyacinthe) division d'enregistrement de St-Hyacinthe.Avis est par la présente donné que le lot 1491 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 7 octobre 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 48801-o AVILA BÉDARD.Department of Lands and Forest* NOTICE Official cadastre of the parish of Beauport (municipality of Beauport-West), registration division of Quebec.Notice is hereby given that lots 560-13 and 565-25 are cancelled in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec, October 7, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD.48801-o Deputy Minister.Official cadastre of the parish of Notre-Dame de L'Assomption de Repentigny (municipality of Repentigny), registration division of L'Assomption.Notice is hereby given that lots 119-3 to 119-25 are cancelled in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec, October 2, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 48801-o Deputy Minister.Official cadastre of the parish of Ste.Foye .(municipality of city of Ste.Foy), registration division of Quebec.Notice is hereby given that lots 181-21-A, 181-21-B, 181-21-C, 181-21 are cancelled in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec, October 7, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD.48801-o Deputy Minister.Official cadastre of village of Windsor Mills (municipality of town of Windsor) registration division of Richmond.Notice is hereby given that lots 465-11, 465-12, 519-1, 519-2, 528-A-l to 528-A-10 are cancelled in virtue of article 2174A- of the Civil Code.Quebec, September 22, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 48801-o Deputy Minister.Official cadastre of the parish of Notre-Dame de St-Hyacinthe (municipality of city of St-Hyacinthe) registration division of St.Hyacinthe.Notice is hereby given that lot 1491 has been added in virtue of article 2174A of the Civil Code.N Quebec, October 7, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 48801-o Deputy Minister. 3572 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1968, Tome 90, N° J& Cadastre officiel du village de Marbleton division d'enregistrement de Wolfe.Avis est par la présente donné que les lots 241 à 251, 253 à 255 et partie de la rue St-Joseph sont annulés et le lot 359 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 17 septembre 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du.Cadastre, Le Sous-ministre, 48801-o AVILA BÉDARD.Département du Travail AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité paritaire de l'industrie de la botte de carton de la province de Québec, établi en exécution du décret numéro 1884 du 12 novembre 1947 et amendements, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1014 du 9 octobre 1958, section \"F\", le tout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements) à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er octobre 1958 au 1er octobre 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 1884 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% du salaire total payé à leurs salariés, y compris bonis, etc.b) Les salariés régis par le décret numéro 1884 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à % de 1% de leur salaire total, y compris bonis, etc.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels, des formules de rapport, lesquelles doivent être remplies selon les règlements du Comité.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient transmis au Comité paritaire à tous les mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la-fin de chaque semaine, à même le salaire de ses salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire, à titre de prélèvement.Le rapport de l'employeur professionnel, accompagné des cotisations, doit être signé et adressé au Comité paritaire dans un délai de quinze (15) jours après l'expiration de la période pour laquelle il est exigible.Le Comité paritaire a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos._ 3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations Officiai cadastre of village of Marbleton registration division of Wolfe.Notice is hereby given that lots 241 to 251, 253 to 255 and part of St.Joseph Street are cancelled and lot 359 has been added in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec, September 17, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÊDARD, 48801-o Deputy Minister.Department of Labour NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Paper Box Industry of the Province of Quebec, formed under decree No.1884 of November 12th, 1947, and amendments, has been authorized by a by-law approved by Order in Council No.1014 of October 9, 1958, part \"F\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers and the employees governed by the said decree according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Assessments The period of levy extends from October 1, 1958, to October 1, 1959; it shall be laid as follows: a) The professional employers governed by to decree No.1884, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to % of 1% of the total wages paid to their employees, including bonuses, etc.6) The employees governed by the decree No.1884, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Y% of 1% of their total wages paid to their employees, including bonuses, etc.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee shall supply the professional employers with report forms to be filled in accordance with the by-laws of the Committee.The professional employer shall have the reports sent to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, from the wages of each one of his employees, the assessments owed to the Parity Committee.The report of the professional employer, together with the assessments, shall be signed and sent to the Parity Committee within the fifteen (15) days following the date of expiration of the period for which it is exigible.The Parity Committee has the right to require sworn reports when deemed advisable.3.Financial report Under the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall make a quarterly report covering its financial operations and remit same QUEBEC OFFICIAI, GAZETTE, Quebec, October 18th, 1958, Vol.90, No.42 3573 financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire de l'Industrie de la Botte de Carton de la province de Québec, pour la période comprise entre le 1er octobre 1958 et le 1er octobre 1959.Le Comité paritaire de l'Industrie de la Boîte de Carton de la province de Québec État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er octobre 1958 et le 1er octobre 1959.Recettes: Cotisations de 1%): Employeurs professionnels.$12,000.00 Salariés.12,000.00 $24.000.00 Déboursés: Salaires: Secrétaire.$ 4,100.00 .Assistant-secrétaire.3,300.00 Inspecteur (Zone I).2,800.00 Sténographe.1,800.00 Commis.1,620.00 Loyer.1,750.00 Taxe d'affaires.90.00 Service téléphonique et éclairage.140.00 Frais de déplacement, inspecteur.400.00 Frais judiciaires et professionnels.500.00 Réserve, créances douteuses.100.00 Impression et papeterie.600.00 Frais de déplacement des membres, jetons de présence, etc.5,000.00 Timbres-poste, téléphone, L.D.et télégrammes.200.00 Divers.550.00 $22.950.00 Surplus, Réserve.1,050.00 824,000.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 18 octobre 1958.48822-o Département de la Voirie to the Minister of Labour on the following date: March 31, June 30, September 30 and Deceml>er 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of the Paper Box Industry of the Province of QOTbec for the period between October 1, 1958 and October 1, 1959.Joint Committee of the Paper Box Industry of the Province of Quebec Probable receipts and expenses for the period from October 1, 1958, to October 1, 1959.Receipts: Assessments of 1%) : Professional employers.$12,000.00 Employees.12,000.00 $24,000.00 Expenses: Salaries: Secretary.:.$ 4,100.00 Assistant-secretary.3,300.00 Inspector (Zone I).2,800.00 Stenographer.1,800.00 Clerk.1,620.00 Rent.1,750.00 Business tax.90.00 Telephone and lighting.140.00 Travelling expenses of inspector.400.00 Professional and judicial fees.500.00 Reserve, uncertain credits.100.00 Printing and stationery.600.00 Travelling, meeting and other expenses of members.5,000.00 Postage, L.D\u201e telephone, telegraph 200.00 Miscellaneous.550.00 822,950.00 Surplus, Reserve.1,050.00 824,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, October 18, 1958.48822-o Department of Roads AVIS Le ministère de la Voirie cessera à l'avenir d'entretenir les sections de routes ci-après désignées, parce qu'elles sont devenues inutiles pour la circulation: Route N° 3 \u2014 Lévis-St-Lambert-Dundee: Dans la municipalité du village de Deschaillons, comté de Lotbinière: Une section de 580 pieds, au nord de la nouvelle route, sur ou vis-à-vis le lot N° 222; une section de 760 pieds, au nord-ouest de la nouvelle route, sur ou vis-à-vis les lots Nos 203, 204 et P.205; une section de 355 pieds, au sud-est de la nouvelle route, sur ou vis-à-vis les lots Nos 187 et 188; une section de 395 pieds, au sud-est de la nouvelle route, sur ou vis-à-vis le lot N° 208; une section de 425 pieds, au nord-ouest de la nouvelle route, sur ou vis-à-vis les lots Nos P.209 et 208-209-210-211-212.NOTICE The Department of Roads shall cease hereafter to maintain sections of roads hereinafter designated because the have become useless to traffic: Route No.3 \u2014 Levis-St-Lambert-Dundee^ In the municipality of the village of Deschaillons, county of Lotbinière: A section of 580 feet, north of the new route, on or facing lot No.222; a section of 760 feet, northwest of the new route, on or facing lots No.203, 204 and P.205; a section of 355 feet, southeast of the new route, on or facing lots No.187 and 188; a section of 395 feet, southeast of the new route, on or facing lot No.208; a sectjon 425 feet, northwest of the new route, on or facing lots No.P.209 and 208-209-210-211-212. 3574 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1968, Tome 90, N° 42 Route No 13 \u2014 Trois-Rivières-Drummond-ville-Acton Vale-Cowansville-Abercorn : Dans la municipalité du village de Wickham, comt'é de Drummond: Une section de 900 pieds, au nord-ouest de la nouvelle route, sur ou vis-à-vis les lots No 568 et P.565.Route N° 55 \u2014Tour du Lac St-Jean: Dans la municipalité de Roberval; comté de Roberval: Une section de 165 pieds, à l'ouest de la nouvelle route, sur ou vis-à-vis le lot N° 36.Dans la municipalité de la cité de Roberval, comté de Roberval: Une section de 110 pieds, à l'ouest de la nouvelle route, sur ou vis-à-vis le lot N° 36.Québec, le 6 octobre 1958.Le Ministre de la Voirie, 48823-0 ANTONIO TALBOT.Route No.13 \u2014 Trois-Rivières-Dmmmond-ville-Acton Vale-Cowansville-Abercorn : In the municipality of the village of Wickham, county of Drummond: A section of 900 feet, northwest of the new route, on or facing lots No.568 and P 565.Route No.55 \u2014 Tour of Lake St.John: In the municipality of Roberval, county of Roberval: A section of 165 feet, west of the new route, on or facing lot No.36.In the municipality of the city of Roberval, county of Roberval: A section of 110 feet, west of the new route, on or facing Jot No.36.Quebec, October 6, 1958.ANTONIO TALBOT, 48823 Department of Roads.Examen du Barreau Bar Examination BARREAU DE MONTRÉAL \u2014 BAR OF MONTREAL Candidats poub l'admission à.l'étude du droit Candidates fob the admission to the study of law Noms\tPrénoms\t\tRésidence\tCollèges _ .3\t_\tAge\t\u2014\t_ Names\tSurnames\t\tResidence\tColleges Mollot.\t\t24 23\t\tUniversité McGill.Université McGill.\tD.E.\t\t\t \t\t\t\t Montréal, le 8 octobre 1958.\u2014 Montreal, October 8, 1958.48835-0 Le Secrétaire, J.-B.CRÊPEAU, Secretary.Nomination Appointment PRÉSIDENT D'ÉLECTION Il a plû à son Honneur le Lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil exécutif, par commission Sous le Grand Sceau, de faire, pour remplir la charge de président d'élection, la nomination suivante: RETURNING-OFFICER His Honour the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the executive Council to appoint by commission under the Great Seal, to fill the office of returning-officer, the person whose names follows: District électoral Electoral district\tNom, prénoms Name, christian names\tProfession ou occupation Profession or calling\tDomicile Domicile Napierville-Laprairie.\tBrossard, Jean (1).\t\tSt-Rémi.(1) En remplacement de M.Léopold-C.Dubuc, démissionnaire.\u2014 In place of Mr.Léopold-C.Dubuc, résigner.Québec, le 8 octobre 1958.Quebec, October 8th, 1958.Le Président général des élections, FRANÇOIS DROUIN, Q.C., 48799-0 FRANÇOIS DROUIN, C.R.48799-o Chief Returning-Oflîcer.Proclamations Proclamations Canada, \u2022 Province de Québec.JL.S.] O.GAGNON Canada, Province of Quebec.[L.S.] O.GAGNON ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses God of the United Kingdom, Canada and Her QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1958, Vol.90, No.1,2 3575 autres royaumes et territoires, Chef du Com- other Realms and Territories Queen, Head monwealth, Défenseur de la foi.' of the Commonwealth, Defender of the Faith.A nos très aimés et fidèles conseillers les mem- To our Beloved and Faithful Councilors, the bres au Conseil législatif et dé l'Assemblée légis- members of the Legislative Council and of the lative de la province de Québec, Legislative Assembly of the Province of Quebec.Salut.Greeting.Attendu que, pour diverses considérations, il est à propos de convoquer la Législature de la province de Québec pour l'expédition des affaires, Nous vous convoquons par les présentes pour le dix-neuvième jour de novembre prochain et, en conséquence, vous mandons et ordonnons de vous assembler à cette date au palais législatif, en la cité de Québec, pour y expédier les affaires de la Province et y examiner, discuter et décider les questions qui vous seront soumises.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de la province de Québec.Whereas for various considerations, it is expedient to convok^ the Legislature of the Province of Quebec for the dispatch of business, We hereby cohyene you for the nineteenth day of November next and, accordingly, command and order you to meet on said date at the Parliament Buildings, in the City of Quebec, for the dispatch of the business of the Province and to examine, discuss and decide the questions to be submitted to you.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made patent and the Great Seal of Our Province of Quebec to be hereunto affixed.Témoin: Notre fidèle et bien-aimé l'honorable Witness: Our right Trusty and Well Beloved, ONÉSIME GAGNON, CP., C.R., lieute- The Honourable Mr.ONESIME GAGNON, nant-gouverneur de ladite Province.P.C., Q.C., Lieutenant-Governor of the said Province.Donné en Notre hôtel du gouvernement, à Québec, le vingt-septième jour d'août, l'an de grâce mil neuf cent cinquante-huit et de Notre règne le septième.Par ordre, Le Secrétaire de la Chancellerie, «I (^Uel)C(' 48527-36-1 l-o ANTOINE LEMIEUX.Given at Our Government House in Quebec, the twenty-seventh day of August, in the year of Our Lord, nineteen hundred and fifty-eight and seventh year of Our Reign.By command, ANTOINE LEMIEUX, Clerk of the Crown in Chancery, 48527-36-11 at Quebec.Canada, Province de Québec.[L.S.] O.GAGNON Canada, Province of Quebec.[L.S.] O.GAGNON ELIZABETH DEUX, par la grace de Dieu, ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses God of the United Kingdom, Canada and Her autres royaumes et territoires, Chef du Com- other Realms and Territories, Queen, Head of monwealth, Défenseur de la foi.Commonwealth, Defender of the Faith.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou To all to whom, these present letters shall qu'icelles pourront concerner, come or whom the same may concern, Salut.Greeting.PROCLAMATION L Assistant-procureur l ATTENDU qu'une général, ) demande Nous a C.E.Cantin, ] été faite à Tefld de detacher le territoire ci-après décrit de la municipalité de la paroisse de Saint-Benolt-Joseph-Labre, dans le comté municipal de Matapédia, et de l'annexer à la municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-du-Lac, dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 9 juillet 1958, portant le numéro 739, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre provinceide Québec, Nous déclarons et décrétons par les présentes, PROCLAMATION C.E.Cantin, ( Vl/HEREAS We have been Deputy Attorney 1 W requested to detach the General.\\ territory hereinafter described \\ from the municipality of the parish of Saint-Benoît-Joseph-Labre, in the municipal county of Matapédia, and annex it to the municipality of the parish of Saint-Pierre-du-Lac, in the same municipal county; Whereas all formalities prescribed by law in this respect have been fulfilled; Whereas it is expedient that his request be granted; Whereas under section 42 of the Municipal Code, the present Proclamation shall enter into force on the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree, dated July 9th, 1958, bearing number 739, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact. $576 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958, Tome 90, N° 42 Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans le canton de Nemtayé, comprenant, en référence au cadastre officiel pour ledit canton, les lots H, I, J, K, L, M, N, O, rang IV, et les lots H, I, J, rang III, du canton de Nemtayé, ainsi que les chemins, cours d'eau ou partie d'iceux, renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne séparant le canton de Nemtayé de la Seigneurie du Lac Matapédia avec la ligne separative des lots G et H du rang III; de là, successivement, ladite ligne séparant le canton de Nemtayé de la Seigneurie du Lac Matapédia en allant vers l'est jusqu'à la ligne separative des rangs IV et V; cette dernière ligne et enfin, la ligne separative des lots G et H de chacun des rangs IV et III jusqu'au point de départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché de la municipalité de la paroisse de Saint-Benoit-Joseph-Labre, dans le comté municipal de Matapédia, et sera annexé à la municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-du-Lac, dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Quebec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable ONÉSIME GAGNON, CP., C.R., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce septième jour d'octobre en l'année mil neuf cent cinquante-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la septième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la province, 48799-0 JEAN BRUCHESI.Canada, Province de O.GAGNON Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut.PROCLAMATION L'Asrirtant-procureurt ATTENDU qu'une général, ) demande Nous a C.E.Cantin.Jeté faite à l'effet d'an-' nexer le territoire ci-après décrit à la municipalité de la paroisse de Sainte-Êmélie-de-1' Énergie, dans le comté municipal de Joliette; Attendu que ce territoire n'est pas actuellement organisé en municipalité; That the following territory, to wit: A territory situated in the township of Nemtayé, comprising, with reference, to the official cadaster for the said township, lots H, I, J, K, L, M, N, O, range IV, and lots H, I, J, range HI, of the township of Nemtayé, as well as the roads, water-courses or part thereof, enclosed within the following limits, to wit: starting from a point at the intersection of the line dividing the township of Nemtayé from the Seigniory of Lake Matapédia with the dividing line of lots G and H of range III; thence, successively, the said line dividing the township of the township of Nemtayé of the seigniory of Lake Matapédia going towards the cast to the dividing line of ranges IV and V; this latter line, and finally the dividing line of lots G and H of each of the ranges IV and III as far as the starting point; which territory shall, as from the first day of January following the date of the publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, be detached from the municipality of the parish of Saint-Benott-Joseph-Labre, in the municipal county of Matapédia, and shall be annexed to the municipality of the parish of Saint-Pierre-du-Lac, in the same municipal county.That this Proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all which Our loving subjects and all others- whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made patent, and the Great Seal of the Province of Quebec, to' be hereunto affixed; Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable ONÉSIME GAGNON, CP., Q.C, Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this seventh day of October, in the yearjrf Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-seventh year of Our Reign.By Command, ' JEAN BRUCHÉSI, 48799 Under Secretary of the Province.Canada, Province of O.GAGNON Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdon, Canada and Her other Realms and Territories, Queen, Head of Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these present letters shall come or whom the same may concern, Greeting.PROCLAMATION C.E.Cantin, ( T\\7HEREAS We have been Deputy Attorney) Vv requested to annex General.\\ the territory hereinafter described to the municipality of the parish of Sai n te-Émélie-ded' Énergie, in the municipal county of Joliette; Whereas this territory, is not presently organized as a municipality; QUEBEC OFFICÎAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1958, Vol.90, No.1,2 3577 Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu qu'il est opportun de se rendre à cette demande; * -Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 9 juillet 1958, portant le numéro 739, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: \u2014 Un territoire situé dans le canton de Tracy, ne faisant actuellement partie d'aucune municipalité locale, comprenant, en référence au cadastre officiel d'une partie du canton de Tracy, tous les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, rivières, cours d'eau, ou parties d'iceux, ainsi qu'un territoire non encore divisé, le tout renfermé dans les limites suivantes, à savoir: Partant du coin nord du lot 42, rang I; de là, passant successivement par les lignes et démarcations suivantes: la ligne extérieure nord-est du canton de Tracy jusqu'au coin est du canton, la ligne extérieure sud-est dudit canton, la ligne % extérieure sud-ouest dudit canton jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 42, rang I, et enfin, ledit prolongement et ladite ligne nord-ouest du lot 42, rang I, jusqu'au point de départ; lequel territoire (non organisé) sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, annexé à la municipalité de la paroisse de Sainte-Émélie-de-l'E-nergie, dans le comté municipal de Joliette; Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de\" Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable ONÊSIME GAGNON, CP., C.R.Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce septième jour d'octobre en l'année mil neuf cent cinquante-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la septième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la province, 48799-0 JEAN BRUCHÉSI.Whereas the formalities prescribed by law in this respect have been complied with; Whereas it is deemed advisable to grant this request; Whereas under section 42 of the Municipal Code, the present Proclamation shall enter into force on the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council expressed in a decree dated July 9, 1958, bearing number 739, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact; That the following territory, to wit: A territory situated in the township of Tracy, not forming part of any local municipality presently, comprising, with reference to the official cadastre of a part of the township of Tracy, all lots or parts thereof and their present and future subdivisions, including roads, rivers, streams or parts thereof, as well as a territory not as yet divided, all of which located within the following boundaries, to wit: Commencing at the northerly corner of lot 42, range I; thence, passing successively by the following lines and demarcations: the outer northeasterly line of the township of Tracy as far as the easterly corner of the township, the outer southeasterly corner of said township, the outer southwesterly line of said township as far as the prolongation of the northwesterly line of lot 42, range I, and finally, the said prolongation and said ¦ northwesterly line of lot 42, range I, as far as the point of commencement; which territory (unorganized) shall, as from the first day of January following the date of publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, be annexed to the municipality of the parish of Sainte-Émélie-de-1' Énergie, in the -municipal county of Joliette; That this Proclamation shall come into force on the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette; Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our letters to be made patent, and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed: Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable ONÊSIME GAGNON, P.C., Q.C., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this seventh day of October, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-eight and the seventh year of Our Reign.By command, JEAN BRUCHÉSI, 48799 Under Secretary of the Province. 3578 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958, Tome 90, N° 48 Sièges sociaux Avis de changement du siège social (Loi des Compagnies à Fonds Social Étrangères) Re: Burgess Battery Company R.T.Collins Builders, Ltd.\" Converted Rice, Inc.Eastern Machine Products Limited General Mills, Inc.J.M.Huber Corporation A.M.Kidder & Co., Inc.Koppers Products, Limited Kyanize Paints, Inc.Leonard Construction Company Machinery Service Corporation New York Central Transport Company Norton Company Pan American World Airways, Inc.The Penetryn System, Inc.Pinkerton's National Detective Agency, Inc.Proctor Engineering Company Tuition Plan, Inc.Wheelabrator Corporation Yellow Manufacturing Acceptance Corporation Head Offices Notice op change of head office (Extra-Provincial Companies' Act) Re: Burgess Battery Company R.T.Collins Builders, Ltd.' Converted Rice, Inc.Eastern Machine Products Limited General Mills, Inc.J.M.Huber Corporation A.M.Kidder & Co., Inc.Koppers Products, Limited Kyanizc Paints, Inc.Leonard Construction Company Machinery Service Corporation New York Central Transport Company Norton Company Pan American World Airways, Inc.The Penetryn System, Inc.Pinkerton's National Detective Agency, Inc.Proctor Engineering Company Tuition Plan, Inc.Wheelabrator Corporation Yellow Manufacturing Acceptance Corporation Avis est, par les présentes, donné que chacune Notice is hereby given that each of the twenty des vingt compagnies ci-dessus mentionnées, above-mentioned companies, duly licensed to do dûment autorisées à exercer leur commerce dans business in the Province of Quebec under the la province de Québec en vertu de l'autorité de authority of the Extra-Provincial Companies' la Loi des Compagnies à Fonds Social Étrangères Act, has forwarded to the Provincial Secretary, a fait parvenir au Secrétaire de la province, con- pursuant to the provisions of the said Act, a copy formément aux dispositions de ladite loi, une of a new power of attorney confirming the cons-copie d'une nouvelle procuration qui confirme titution of Mr.W.H.Laidley heretofore of 2000 la constitution de M.W.H.Laidley auparavant Aldred Building, Montreal, and now at Room à 2000 Édifice Aldred, Montréal, et maintenant à 300, 455 Craig Street West, Montreal, Province chambre 300, 455 ouest, rue Craig, Montréal, of Quebec, as its chief agent in the said Province province de Québec, comme son agent principal and declaring that its principal office in the en ladite province et déclare que son bureau Province, previously established at c/o Elder, principal dans cette province, antérieurement Laidley, Leslie, Bourgeois & Doheny, 2000 Aldred établi a/s de Elder, Laidley, Leslie, Bourgeois & Building, in the said.city of Montreal, is now Doheny, 2000 Édifice Aldred, en ladite cité de established at the above given new address, Montréal, est maintenant établi à l'adresse ci- namely: Room 300,' 455 Craig Street West, dessus donnée, à savoir: Chambre 300, 455 ouest, Montreal, 1.rue Craig, Montréal 1./ Donné au bureau du Secrétaire de la province, Given at the office of the Provincial Secretary, ce 10e jour d'octobre 1958.this 10th day of October, 1958.Le Secrétaire de la province, JEAN BRUCHÉSI, 48814 JEAN BRUCHÉSI.48814-o Under-Secretary of the Province.Avis est donné que la Compagnie \"Breal Notice is hereby given that' \"Breal Construc- Construction Limitée\", constituée en corporation tion Limitée\", company incorporated by letters par lettres patentes en date du 5 septembre patent on September 5, 1958, and having its head 1958, et ayant son siège social à Montréal, dis- office in the city of Montreal, district of Montreal, trict de Montréal, a établi son bureau au N° has established its office at 1525 West Blvd 1525 ouest, Boulevard Gouin, en ladite cité.Gouin.> A compter de la date du présent avis, ledit From and after the date of this notice, the said bureau est considéré par la compagnie comme office shall be considered by the company as étant son bureau principal.being the head office of the company.Daté à Montréal, ce 24 septembre 1958.Dated at Montreal, this 5th day of September, 1958.Le Président, ADÊLARD LABRIE, 48815-o ADÊLARD LABRIE.48815-0 President.Avis est donné que la compagnie \"Astra Notice is hereby given that \"Astra Services Services Techniques Inc.\u2014 Astra Technical Techniques Inc.\u2014 Astra Technical Services Services Inc.\", constituée en corporation sous Inc.\", incorporated by letters patent under Part la première partie de la Loi des compagnies de I of the Quebec Companies' Act dated January Québec par lettres patentes en date du 22 jan- 22nd, 1958, has established its head office in vier 1958 a établi son bureau à Montréal, au Montreal, at 515 DeMontigny Street East, numéro 515 est, rue DeMontigny. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1958, Vol.90, No.42 3579 A compter de la date du present avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son principal bureau.Donné à Montréal, ce 9ième jour d'octobre 1958.Le Président, 48816-0 FRANÇOIS BERTRAND.A.Meloche & Filb Ltée A.Meloche & Son Ltd.Avis est donné que la compagnie \"A.Meloche & Fils Ltée\", constituée en corporation sous la Loi des compagnies de Québec, en date du 23ème jour d'avril 1958, et ayant son bureau principal dans Ste-Anne-de-Bellevue, a établi son bureau au numéro 196, rue S te-An ne.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 6ième jour d'octobre 1958.Le Président, 48817-o UBALD MELOCHE.Avis est donné que la compagnie \"Aircraft Specialties Company Limited\" constituée en corporation suivant lettres patentes provinciales, en date du 17 juin 195S, a établi son bureau au numéro 10,330, rue Herri, en la cité de Montréal, district de Montréal, province de Québec.A compter de la date du présent avis ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 27e jour d'août 1958.Le Président, 48818-0 ANTONIO GIROUX.Van de North Ltd-Ltée.Avis de changement d'adresse du siège social Avis est par les présentes donné que la compagnie \"Van de North Ltd-Ltée.\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 9 janvier 1946, et ayant son bureau-chef en la cité de Montréal, au numéro 5451 Upper Lachine Road, où elle avait son bureau-chef jusqu'à aujourd'hui, l'a transporté au numéro 925 rue St-Louis, St-Hyacinthe, à compter de la date du présent avis.Ledit -bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 9ème jour d'octobre 1958.Le Président, 48824-0 L.P.BERGERON.Gatineau Construction Ltée Avis de changement d'adresse Avis est donné que la compagnie \"Gatineau Construction Ltée, constituée en corporation par lettres patentes en date du 14 mars 1956 et ayant son bureau principal dans Gatineau où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 331 de la rue Notre-Dame, l'a transporté au numéro 378 de la rue Notre-Dame.A compter de la date du présent avis ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Gatineau, ce 8ième jour d'octobre 1958.Le Secrétaire-trésorier, 48839-o S.HUNEAULT.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 9th dav of October, 1958.FRANÇOIS BERTRAND, 48816-o President.A.Meloche & Fils Ltée A.Meloche & Son Ltd.Notice is given that the company \"A.Meloche & Son Ltd.\", incorporated under the Quebec Companies' Act, dated April 23, 1958, and having its head office at Ste-Anne-de-Bellevue, has established its office at number 196 Ste-Anne Street.¦From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this sixth day of October, 1958.UBALD MELOCHE, 48817 President.Notice is given that the \"Aircraft Specialties Company Limited\" incorporated according to provincial letters patent dated June 17, 1958, has established its office at number 10,330 Berri Street, in the city of Montreal, district of Montreal, Province of Quebec.From and after the date of the present notice the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 27th day of August, 1958.ANTONIO GIROUX, 48818 President.Van de North Ltd-Ltée.Notice of change in the address of the Head-office.Notice is hereby given that \"Van de North Ltd-Ltée.\" incorporated by letters patent dated January 9th, 1946, and having its head-office in the city of Montreal, at 5451 Upper Lachine Road, .where its office was situated up to-day, they have moved it to 925 St-Louis street, city of St-Hyacinthe, district of St-Hyacinthe.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head-office.Dated at Montreal, this 9th day of October, 1958.L.P.BERGERON, 4S824-0 President.Gatineau Construction Ltée Notice of change of location Notice is given that the company \"Gatineau Construction Ltée\", constituted as a corporation by letters patent dated March 14, 1956 and having its head office in Gatineau, where its office has been situated up to to-day at number 331 Notre-Dame Street, has moved said office to number 378 Notre-Dame Street.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Gatineau, this eighth day of October, 1958.' S.HUNEAULT, 48839 Secretary-Treasurer. 3680 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958, Tome 90, N° 42 W.H.Marbb Inc.Avis est donné que la compagnie \"W.H.M aher Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 26 août 1958 et ayant le principal siège de ses affaires à Montréal, a établi son bureau à 316, rue Bridge, Montréal, District de Montréal, Province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté a Montréal, ce 27 août 1958.La Secrétaire-trésorière, 48854-o GEORGETTE SOUCY.W.H.M aher Inc.Notice is hereby given that \"W.H.Maher Inc.\", company incorporated by letters patent dated the 26th day of August, 1958 and having its chief place of business in Montreal, has established its office at 316 Bridge Street, A'ont real, District of Montreal, Province of Quebec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 27th day of August, 1958.GEORGETTE SOUCY, 48854-o Secretary-treasurer.Pickwood Construction Inc.Avis est donné que la compagnie \"Pickwood Construction Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 3 septembre 1958 et ayant le principal siège de ses affaires, à Montréal, a établi son bureau à 10742, boulevard St-Laurent, Montréal, District de Montréal, Province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté à Montréal, ce 4 septembre 1958.La Secrétaire-trésorière, 48855-0 GEORGETTE SOUCY.Je soussigné.Claude Sarrasin, secrétaire de la compagnie \"Fas Import Ltd\", constituée par lettres patentes émises le 16 juin 1958, déclare ce qui suit: Le siège social de la compagnie sera établi au numéro 2886 rue Masson, en la cité de Montréal, district de Montréal, où se trouvera le domicile de Fas Import Ltd.Montréal, le 25 août 1958.Et j'ai signé : 48856-0 CLAUDE SARRASIN.Soumissions Pickwood Construction Inc.Notice is hereby given that \"Pickwood Construction Inc.\", company incorporated by letters patent dated the 3rd day of September, 1958 and having its chief place of business in M ont real, has established its office at 10742 St.Laurent Boulevard, Montreal, District of Montreal, Province of Quebec.From and after the date of this notice, .the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 4th day of September.1958.GEORGETTE SOUCY, ' 48855-o Secretary-Treasurer.I, the undersigned, Claude Sarrasin, Secretary for the \"Fas Import Ltd\", incorporated by letters patent issued on June 16.1958, declare the following: The head office of the company shall be established at number 2886 Masson Street, in the city of Montreal, district of Montreal, at the domicile of Fas Import Ltd.Montreal.August 25, 1958.and I signed : 48856 CLAUDE SARRASIN.Tenders Province de Québec Les commissaires d'écoles pour la municipalité de St-Louis-de-Gonzaoue (Comté de Beauharnois) Avis public est par lés présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Armand Gascon, N.P., secrétaire-trésorier, St-Louis-de-Gonzague, comté de Bcaidiar-nois, jusqu'à 9.00 heures du soir, mercredi, le 5 novembre 1958, pour l'achat de 896,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de St-Louis-de-Gonzague, comté de Beauharnois, datées du 1er octobre 1958 et remboursables par séries du 1er octobre 1959 au 1er octobre 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% ni supérieur à 5% par année, payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 13 août 1958, telle que modifiée \u2014 construction d'une école de sept classes dans l'arrondissement N° 1.Province of Quebec The school commissioners for the municipality of St-Louis-de-Gonzague (County of Beauharnois) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Armand Gascon, N.P., Secretary-Treasurer, St-Louis-de-Gonzague, county of Beauharnois, until 9.00 o'clock p.m.Wednesday, November 5.1958, for the purchase of an issue of $96,000.00 bonds for the school commissioners of the municipality of St-Louis-de-Gonzague, county of Beauharnois, dated October 1st, 1958, and redeemable serially from October 1st, 1959 to October 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate not less than 4% nor more than 5% per annum, payable semiannually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated August 13, 1958, as amended \u2014 construction of a school of seven classrooms in district No.1. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1968, Vol.90, No.42 3581 Pour fins d'adjudication leulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er décembre-1968.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $96,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er octobre'1959\t.,x $18,500\t00 1er octobre 1960\t.x 19,500\t00 1er octobre 1961\t., x 20,000\t00 1er octobre 1962\t1,500\t00 1er octobre 1963\t1,500\t00 1er octobre 1964 \u2022\t'1,500\t00 1er octobre 1965\t., 2,000\t00 1er octobre 1966\t2,000\t00 1er octobre 1967\t2,000\t00 1er octobre 1968\t2,000\t00 1er octobre 1969\t2,000\t00 1er octobre 1970\t2,000\t00 1er octobre 1971\t2,000\t00 \t2,500\t00 1er octobre 1973\t2,500\t00 1er octobre 1974\t2,500\t00 1er octobre 1975.\t3.000\t00 1er octobre 1976.\t3,000\t00 \t3,000\t00 1er octobre 1978\t3,000\t00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total dç $58,857.75 accordé par le Secrétaire de la province et payable en trois versements de $19,-619.25 chacun, de 1959 à 1961 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il* y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Yalleyfield, comté de Beauharnois.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er octobre 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.I.es soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mercredi, le 5 novembre 1958 à 9.00 heures du soir, au bureau du secrétaire-trésorier, St-Louis-de-Gonzague, comté de Beauharnois.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Louis-de-Gonzague, (Comté de Beauharnois), ce 14 octobre 1958.Le Secrétaire-trésorier, ARMAND GASCON, N.P.St-Louis-de-Gonzague, (Beauharnois), P.Q., Téléphone : FRontenac 3-3505.48825-o For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from December 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $96,000.00 \u2014 20 years Year Capital October 1st, 1959.x $18,500.00 October 1 st, 1960.x 19,500.00 October 1st, 1961.x 20,000.00 October 1st, 1962.1,500.00 October 1st, 1963.1,500.00 October 1st, 1964.1,500.00 October 1st, 1965 .2,000.00 October 1st, 1966.2,000.00 October 1st, 1967.2,000.00 October 1st, 1968.2,000.00 October 1st, 1969.2,000.00 October 1st, 1970 .2,000.00 October 1st, 1971.2,000.00 .October 1st, 1972 .2,500.00 October 1st, 1973 .2,500.00 October 1st, 1974 .2,500.00 October 1 st, 1975 .3,000.00 October 1st, 1976 .3,000.00 October 1 st, 1977 .3,000.00 October 1 st, 1978 .3,000.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of 858,857.75 granted by the Provincial Secretary and payable in three instalments of $19,619.25 each, from 1959 to 1961 inclusively, will be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Valleyfield, county of Beauharnois.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior to October 1st, 1968 inclusively; after which dates the bonds are, under authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Wednesday, November 5, 1958, at 9.00 o'clock p.m., at the office of the Secretary-Treasurer, St-Louis-de-Gonzague, county of Beauharnois.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.St-Louis-de-Gonzague, (County of Beauharnois), October 14, 1958.ARMAND GASCON, N.P., Secretary-Treasurer.St-Louis-de-Gonzague, (Beauharnois), P.Q., Telephone: FRontenac 3-3505.48825 3582 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1968, Tome 90, N° # Province de Québec Cantons Unis de Salaberrt & Grandison (Comté de Terrebonne) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Donat Léonard, secrétaire-trésorier, St-Jovite, comté de Terrebonne, jusqu'à 7.00 heures du soir, lundi, le 3 novembre 1958, pour l'achat de $20,000.00 d'obligations des Cantons Unis de Salaberry & Grandison, comté de Terrebonne, datées du 1er novembre 1958 et remboursables par séries du 1er novembre 1959 au 1er novembre 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4^% ni supérieur à 5^% par année, payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt N° 196 \u2014 travaux d'aqueduc.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er décembre 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $20,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er novembre 1959.$ 500.00 1er novembre 1960.500.00 1er novembre 1961.500.00 1er novembre 1962.500.00 1er novembre 1963.500.00 1er novembre 1964.1,000.00 1er novembre 1965.1,000.00 1er novembre 1966.1,000.00 1er novembre 1967.1,000.00 1er novembre 1968.1,000.00 1er novembre 1969.1,000.00 1er novembre 1970.1,000.00 1er novembre 1971.1,000.00 1er novembre 1972.1,000.00 1er novembre 1973.1,000.00 1er novembre 1974.1,500.00 1er novembre 1975.1,500.00 1er novembre 1976.1,500.00 1er novembre 1977.1,500.00 1er novembre 1978.1,500.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Jovite, comté de Terrebonne.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er novembre 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus, sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 3 Province of Quebec United Townships op Salaberry & Grandison (County of Terrebonne) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Donat Léonard, Secretary-Treasurer, St-Jovite, county of Terrebonne, until 7.00 o'clock p.m.Monday, November 3, 1958, for the purchase of an issue of $20,000.00 of bonds for the United Townships of Salaberry & Grandison, county of Terrebonne, dated November 1st, 1958, and redeemable serially from November 1st, 1959 to November 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate not less than 4^% nor more than 5%% per annum, payable semi-annually oh May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law No.196 \u2014 work on aqueduct.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from December 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $20,000.00 \u2014 20 years Year Capital November 1st,\t1959.,.\t, $ 500.00 November 1st,\t1960 ,\t500.00 November 1st,\t1961\t500.00 November 1st,\t1962.\t500.00 November 1st,\t1963 , ,\t500.00 November 1st,\t1964.\t.1,000.00 \u2022 November 1st,\t1965,., .\t.1,000.00 November 1st,\t1966 .\t., 1,000.00 November 1st,\t1967 .,\t, 1,000.00 November 1st,\t1968\t.1,000.00 November 1st,\t1969.\t.1,000.00 November 1st,\t1970.\t., 1,000.00 November 1st,\t1971\t1,000.00 November 1st,\t1972\t.1,000.00 November 1st,\t1973., .\t, , 1,000.00 November 1st,\t1974\t, .1,500.00 November 1st,\t1975\t1,500.00 November 1st,\t1976\t.1,500.00 November 1st,\t1977____\t.1,500.00 November 1st,\t1078 ,\t.1,500.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at St.Jovite, county of Terrebonne.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior to November 1st, 1968 inclusively, after.which.dates the bonds are, under authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however', in case of partiel redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council, to be held on Monday, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1958, Vol.90, No.42 3583 novembre 1958, à 7.00 heures du soir, à l'école Notre-Dame, St-Jovite, comté de Terrebonne.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Jovite, (Comté de Terrebonne), ce 15 octobre 1958.Le Secrétaire-trésorier, DONAT LÉONARD.Adresse postale: CP.147, St-Jovite, (Terrebonne), P.Q.Téléphone: 457 à St-Jovite.48849-0 Province de Québec Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la cité de Chicoutimi (Comté de Chicoutimi) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Joseph Bonneau, secrétaire-trésorier, 36 est, rue Jacques-Cartier, Chicoutimi, comté de Chicoutimi, jusqu'à 4 00 heures de l'après-midi, mardi, le 4 novembre 1958, pour l'achat de $130,000.-00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de-la cité de Chicoutimi, comté de Chicoutimi, datées du 1er septembre 1958 et remboursables par séries du 1er septembre 1959 au 1er septembre 1973 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% ni supérieur à 5% par année, payable semi-annuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toutes l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 21 juillet 1958 \u2014 construction d'une école dans le quartier Murdock.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er décembre 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $180,000.00 \u2014 15 ans Année Capital 1er septembre 1959.x$25,000.00 1er septembre 1960.x 26,000.00 1er septembre 1961.x 27,000.00 1er segtembre 1962 .3,000.00 1er septembre 1963.4,000.00 1er septembre 1964 .4,000.00 1er septembre 1965 .4,000.00 1er septembre 1966 .4,000.00 1 er septembre 1967 .4,000.00 1er septembre 1968.4,000.00 1er septembre 1969.5,000.00 1er septembre 1970 .5,000.00 1er septembre 1971.5,000.00 1er septembre 1972 .5,000.00 1er septembre 1973 .5,000.00 Les \"x1\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $75,-000.00, accordé par le Secrétaire de la province et payable en trois versements de $25,000.00 chacun, de 1959 à 1961 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.# L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Chicoutimi, comté de Chicoutimi.Le capital et lés intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.November, 3, 1958, a't 7.00 o'clock p.m., at the Notre-Dame School, St.Jovite, county of Terrebonne., The Council does not bind itself tb accept the highest or any of the tenders.St-Jovite, (County of Terrebonne), October 15, 1958.DONAT LEONARD, Secretary-Treasurer.Postal address: P.O.B.147, St-Jovite, (Terrebonne), P.Q.Telephone: 457 at St-Jovite.48849 Province of Quebec The school commissioners for the Municipality of the city of Chicoutimi (County of Chicoutimi) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the un Ii rsigned Josep'i Bonneau, Secretary-Treasurer, 36 Jacques-Cartier East, Chicoutimi, county of Chicoutimi, until 4.00 o'clock p.m.Tuesday, November 4, 1958, for the purchase of an issue of $130,000.00 of bonds for the School Commissioners for the municipality of the city of Chicoutimi, county of Chicoutimi, dated September 1st, 1958, and redeemable serially from September 1st, 1959 to September / 1st, 1973 inclusively, with interest at a rate not less than 4% nor more than 5% per annum, payable semiannually on March 1st and September 1st of each year.-The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated July 21, 1958 - construction of a school in the Murdock district.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from December 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $180,000.00 \u2014 15 years Year Capital September 1st, 1959 .x$25,000.00 September 1st, 1960 .'.x 26,000.00 September 1st, 1961 .x 27,000.00 September 1st, 1962 .3,000.00 September 1st, 1963 .4,000.00 \u2022 September 1st, 1964 .4,000.00 September 1st, 1960 .4,000.00 September 1st, 1966 .4,000.00 September 1st, 1967 .4,000.00 September 1st, 1968 .4,000.00 September 1st, 1969 .5,000.00 September 1st, 1970 .5,000.00 September 1st, 1971 .5,000.00 Septembre 1st, 1972 .5,000.00 September 1st, 1973 .5,000.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $75,000.00 granted by the Provincial Secretary and payable in three instalments of $25,000.00.from 1959 to 1961 inclusively, will be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds: principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Chicoutimi, county of Chicoutimi.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure as^ well as the head office of the said bank at Toronto. 3584 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1968, Tome 90, N° 42 Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er septembre 1966 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 4 novembre 1958, à 4.00 heures de l'après-midi, en l'école St-Michel, 36 est, rue Jacques-Cartier, Chicoutimi, comté de Chicoutimi.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Chicoutimi, (Comté de Chicoutimi), ce 15 octobre 1958.Le Secrétaire-trésorier, JOSEPH BONNEAU.36 est, rue Jacques-Cartier, Chicoutimi, (Chicoutimi), P.Q.Téléphone: Liberté 3-5017.48850-o Province de Québec Ville de Dorion (Comté de Vaudreuil) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, E.-A.Caron, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, 130 rue St-Çharles, Dorion, comté de Vaudreuil.jusqu'à 7.30 heures du soir, mercredi, le 5 novembre 1958, pour l'achat de 8234,000.00 d'obligations de la ville de Dorion, comté de Vaudreuil.datées du 1er décembre 1958 et remboursables par séries du 1er décembre 1959 au 1er décembre 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4-H>% ni supérieur à 5^?% par année, payable semi-annuel lenient les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux «l'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements d'emprunt Nos: 227 \u2014 8144,000.00 travaux de rues et drainage; 233 \u2014 89.200.00, construction d'égouts; 234 \u2014 89,500.00, construction d'égouts et d'aqueduc; 237 \u2014 $6,500.00, construction d'aqueduc; 238 \u2014 $32.000.00, construction d'égouts; 239 \u2014 $10,000.00, construction d'égouts; 240 \u2014 $6,000.00, construction d'égouts; 241 \u2014 $3 200.00, construction d'égouts; et 242 \u2014 $14,000.00, construction d'égouts.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er décembre 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 S234.000.00 ~ 20 ans Année Capital 1er décembre 1959.$ 7,000.00 1er décembre 1960.8.000.00 1er décembre 1961.8.000.00 1er décembre 1962 .9.000.00 1er décembre 1963 .9.000.00 1 er décembre 1964.9.000.00 1 er décembre 1965.41.000.00 The said bonds will not be redeemable by anticipation prior to September 1st, 1966 inclusively, after which dates the bonds are, under authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed- by anticipation, in whele-or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price.of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Tuesday, November 4, 1958, at 4.00 o'clock p.m., at the St-Michael's School, 36 East Jacques-Cartier Street, Chicoutimi, County of Chicoutimi.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Chicoutimi, (County of Chicoutimi), October 15, 1958.JOSEPH BONNEAU, Secretary-Treasurer.36 East Jacques-Cartier Street, Chicoutimi, (Chicoutimi) P.Q.Telephone: Liberté 3-5017.48850 Province of Quebec Town of Dorion (County of Vaudreuil) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, E.-A.Caron, Secretary-Treasurer, City Hall, 130 St.Charles Street, Dorion, county of Vaudreuil, until 7.30 o'clock p.m., Wednesday, November 5, 1958, for the purchase of an issue of $234,000.00 of bonds of the town of Dorion, county of Vaudreuil, dated December 1st, 1958 and redeemable serially from December 1st, 1959 to December 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate of not less than 4^2%.or more than SH% per annum, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-laws Nos 227 \u2014 $144,000.00, street and draining operations; 233 \u2014 $9,200.00, building of sewers; 234 \u2014 $9,500.00.building of waterworks and sewers; 237 \u2014 $6,500.00, building of waterworks; 238 \u2014 $32,000.00, building of sewers; 239 \u2014 $10,000.00 \u2014 building of sewers; 240 \u2014 $6.000.00, building of sewers; 241 \u2014 $3,200.00 building of sewers; and 242 \u2014 $14,000.00, building of sewers.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from December 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $234,000.00 \u2014 20 years Year Capital December 1st, 1959.$ 7,000.00 December 1 st, 1960 .8,000.00 December 1st, 1961.8,000.00 December 1 st, 1962 .9,000.00 December 1 st, 1963 .9,000.00 December 1 st, 1964 .9,000.00 December 1st, 1965 .9,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1958, Vol.90, No.Ifi 3585 1er décembre 1966 1er décembre 1967 1er décembre 1968 1er décembre 1969 1er décembre 1970 1er décembre 1971 1er décembre 1972 1er décembre 1973 1er décembre 1974 1er décembre 1975 1er décembre 1976 1er décembre 1977 1er décembre 1978 > 9,500.00 10.500.00 10,500.00 11,500.00 12,000.00 13,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 15,500.00 17,000.00 17,000.00 December 1st, 1966 December 1st, 1967 December 1st, 1968 December 1st, 1969 December 1st, 1970 December 1st, 1971 December 1st, 1972 December 1st, 1973 December 1st, 1974 December 1st, 1975 December 1st, 1976 December 1st, 1977 December 1st, 1978 9,500.00 10,500.00 10,500.00 11,500.00 12,000.00 13,500.00 ^ 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 15,500.00 17,000.00 17,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, The successful tenderer agrees to pay for the capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque bonds, principal and accrued interest if any, by visé, payable au pair à Dorion, comté de Vau- certified cheque payable at par at Dorion, county drcuil.of Vaudreuil.Le capital et les intérêts sont payables a toutes Capital and interest are payable at all branches les succursales dans la province de Québec de la in the Province of Quebec of the bank mentioned banque dont le nom est mentionné dans la procé- in the loan procedure, as well as at the head office dure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de of said bank in Toronto, ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables The said bonds ahll not be redeemable by anti-par anticipation avant le 1er décembre 196S cipation prior to December 1st, 1968 inclusively; inclusivement; après cette date, lesdites obliga- after which date the said bonds may, under the tions pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des authority of Chapter 212, Revised Statutes of Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées Quebec, 1941, be redeemed by anticipation, in.par anticipation, en tout ou en partie, au pair, whole or in part, at par, at any interest maturity à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel date; however, in case of partial redemption, the rachat est partiel, il affectera les échéances les bonds to be redeemed will be called for payment plus éloignées et les numéros les plus élevés.in reverse order of maturity and serial number.Chaque soumission devra être accompagnée Each tender must be accompanied by a certified d'un chèque accepté égal à 1% du montant de cheque equal to 1% of the amount of the present l'emprunt et devra spécifier si le prix offert issue and must specify whether interest accrued comprend ou ne comprend pas les intérêts courus on the bonds to the date of their delivery is sur les obligations au moment de leur livraison.included or not in the price of the tender.Les soumissions seront ouvertes et considérées The tenders will be opened and considered at a à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, meeting of the Council to be held on Wednesday, le 5 novembre 1958, à 7.30 heures du soir, en November 5, 1958, at 7.30 o'clock p.m., at the l'Hôtel de Ville, 130 rue St-Charles, Dorion, City Hall, 130 St.Charles Street, Dorion, county comté de Vaudreuil.of Vaudreuil.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la The Council is not bound to accept the highest plus haute ni aucune des soumissions.or any of the tenders.Dorion, (Comté de Vaudreuil), ce 15 octobre Dorion, (County of Vaudreuil), this October 1958.15, 1958.Le Secrétaire-trésorier, E.-A.CARON, E.-A.CARON.Secretary-Treasurer.Adresse postale: Ç.P.188, Post office address: P.B.188, Hôtel de Ville, City Hall, 130 rue St-Charles, 130 St.Charles Street, Dorion, (Vaudreuil), P.Q.Dorion (Vaudreuil), P.Q.Téléphone: 2971.4885l-o Telephone: 2971.48851 Province do Québec Province of Quebec Les commissaires d'écoles pour la The school commissioners for the municipalité de la cité de Thetford Mines municipality of the city of Thetford Mines (Comté de Mégantic) (County of Mégantic) Avis public est, par les présentes, donné que des Public notice is hereby given that sealed ten-soumissions cachetées et endossées \"Soumissions ders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be receiv-pour obligations\" seront reçues par le soussigné, cd by the undersigned Me Antonio Beaudoin, Q.Me Antonio Beaudoin, C.R., secrétaire-trésorier.C, Secretary-treasurer, City Hall, Notre-Dame Hôtel de ville, rue Notre-Dame sud, Thetford Street, South, Thetford Mines, county of Megan-Mines, comté de Mégantic, jusqu'à 8.00 heures du tic, until 8.00 o'clock, p.m., Tuesday, November soir, mardi, le 4 novembre 1958, pour l'achat de 4, 1958, for the purchase of 8282,500.00 of bonds $282,500.00 d'obligations des commissaires d'éco- of the School Commissioners for the Municipality les pour la municipalité de la cité de Thetford of the city of Thetford Mines, county of Megantic, Mines, comté de Mégantic, datées du 1er octobre dated October 1st, 1958, and redeemable serially 1958 et remboursables par séries du 1er octobre from October 1st, 1959 to October 1st, 1978 1959 au 1er octobre 1978 inclusivement, avec in- inclusively, at a rate of not less than 4% or more térêt à un taux non inférieur à 4% ni supérieur than 5% per year payable semi-annually, on à 5% par année, paayble semi-annuellement les April 1st and October 1st of each year.The 1er avril et 1er octobre de chaque année.Létaux rate of interest may be the same for the whole d'intérêt peut être le même pour toute l'émission issue or it may vary according to maturities, ou il peut varier suivant les échéances. 3586 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1968, Tome 90, N° 42 Résolution d'emprunt en date du 19 août 1958, Loan resolution dated August 19, 1958, «s telle que modifiée \u2014 construction de l'école St- amended \u2014 Erection of St.Patrick's School.Patrick.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul For adjudication purposes only; interest shall d'intérêt sera fait à compter du 1er décembre 1958 be calculated as from December 1st, 1958.Lè tableau d'amortissement est le suivant: The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 $282*500.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er octobre 1er octobre 1er octobre 1er octobre le,r octobre 1er octobre 1 er octobre 1 er octobre 1er octobre 1 er octobre 1er octobre 1er octobre 1er Octobre 1er octobre 1er octobre 1er octobre 1er octobre 1 er octobre 1er octobre 1er octobre 1959 .xS29.000.00 1960 .x 30,500.00 1961 .x 32,000.00 1962 .x 33,500.00 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 6.500.00 7.000.00 7,500.00 7,500.00 8.000.00 8,500.00 9.000.00 9.500.00 10,000.00 10.500.00 11,000.00 11.500.00 12.000.00 12.500.00 13,000.00 13,500.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $115,-145.80.accordé par le Secrétaire de la province et payable en quatre versements de 828,786.45 chacun, de 1059 à 1962 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Thetford Mines, comté de Mégantic.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas raehetables par anticipation avant le 1er octobre 1968 inclusivement; après acette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à \\% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouverte set considérées à une séance «les commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 4 novembre 1958, à 8.00 heures du soir, en l'Hôtel de Ville, rue Notre-Dame sud, Thetford Mines, comté de Mégantic.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.^ Thetford Mines, (comté de Mégantic), ce 14 octobre 1958.Le Secrétaire-trésorier, Me ANTONIO BEAUDOIN, C.R., Adresse postale: CP.295, 94 rue Notre-Dame Sud, Thetford-Mines.(Mégantic), P.Q.Téléphone: FÊdéral 5-5321.48852-o Table of redemption \u2014 $282,500.00 \u2014 20 years Year Capital October 1st, 1959.x$29,000.00 October 1st, 1960.'.x 30,500.00 October 1st, 1961.x 32,000.00 October 1st, 1962.x 33,500.00 October 1st, 1963.October 1st, 1964.October 1st, 1965.October 1st, 1966.October 1st, 1967.October 1st, 1968.October 1st, 1969.October 1st, 1970.6,500.00 7,000.00 7,500.00 7,500.00 8,000.00 8,500.00 9,000.00 9,500.00 October 1st, 1971.10,000.00 October 1st, 1972.10,500.00 October 1st, 1973.11,000.00 October 1st, 1974.11,500.00 October 1st, 1975.12,000.00 October 1st, 1976.12,500.00 October 1st, 1977.13,000.00 October 1st, 1978.13,500.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $115,145.80 granted by the Provincial Secretary and payable in four instalments of $28,786.45 each, from 1959 to 1962 inclusively, will be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bounds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Thetford Mines, county of Megantic.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of said bank in Toronto.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior to October 1st, 1968 inclusively; after which date, the said bonds may, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec 1941, be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Tuesday, November 4, 1958 at 8.00 o'clock p.m., at the City Hall, Notre-Dame Street, South, Thetford Mines, county of Megantic.The School Commissioners are not bound to accept the highest or any of the tenders.Thetford Mines, (county of Megantic), this October 14, 1958.Me ANTONIO BEAUDOIN, Q.C, Secretary-Treasurer.Post-Office Address: P.B.295, 94 Notre-Dame Stree, south, Thetford Mines, (Megantic), P.Q.Telephone : FEderal 5-5321.48852 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1958, Vol.90, No.42 3587 Province de Québec Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Saint-François-de-Sales (Comté de Laval) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Lucien Cartier, secrétaire-trésorier, jusqu'à 7 heures 30 du soir, à 6830 Boulevard des Mille-Iles, Saint-François-de-Sales (Laval), ou jusqu'à 8.00 heures du soir, à l'école Boileau, Saint-François-de-Sales (Laval), mercredi, 5 novembre 1958.pour l'achat de S 140.000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de Saint-François-de-Sales, comté de Laval, datées du 1er octobre 1958 et remboursables par séries du 1er octobre 1959 au 1er octobre 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% ni supérieur à 5% par année, payable semi-annucllement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 28 juillet 1958 \u2014 construction d'une école élémentaire «le huit classes.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er décembre 1958.Le tableau «l'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $140.000.00 \u2014 20 ans Année\t\tCapital 1er octobre 1959.\t.x\t816,000.00 1er octobre 1960\t.x\t16.000.00 1er octobre 1961.\t.x\t16,000.00 1er octobre 1962\t.x\t16,000.00 1er.octobre 1963.\t.x\t17.000.00 1er octobre 1964.\t\t2,500.00 1er octobre 1965.\t\t2.500.00 1er octobre 1966.\t\t3,000.00 1er octobre 1967.\t\t3.000.00 1er octobre 1968.\t\t3.500.00 1er octobre 1969\t\t3.500.00 1er octobre 1970.\t\t3.500.00 1er octobre 1971.\t\t4,000.00 1er octobre 1972.\t\t4,000.00 1er octobre 1973.\t\t4,500.00 1er octobre 1974.\t\t5.000.00 1er octobre 1975.\t\t5.000.00 1er octobre 1976.\t\t5,000.00 1er octobre 1977.\t\t5.000.00 1er octobre 1978.\t\t5.000.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi de $80,944.50, accordé par le Secrétaire de la province et payable en cinq versements de $16,188.90 chacun, de 1959 à 1963 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Terrebonne, comté de Terrebonne.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachctables par anticipation avant le 1er octobre 196S inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité «lu chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances Province of Quebec The school commissioners for the municipality of Saint-Fran«^)is-de-Sales (County of Laval) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Lucien Cartier, secretary-treasurer, until 7.30 o'clock p.m., at 6830 Mille-Ues Boulevard, Saint-François-de-Sales (Laval), or 8.00 o'clock p.m., at Boileau School, Saint-François-de-Sales (Laval), Wed-nestlay, November 5, 1958, for the purchase of $140,000.00 of bonds of the school commissioners for the municipality of Saint-François-de-Sales, county of Laval, dated October 1st, 1958 and redeemable serially from October 1st, 1959 to October 1st, 1978 inclusively, at a rate of not less than 4% or more than 5% payable semiannually, on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated July 28, 1958 \u2014 Erection of an elementary school of eight classes.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from December 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 8140,000.00 \u2014 20 years Year\t\tCapital October 1st, 1959.\t____x\t$16,000.00 October 1st, 1960.\t.x\t16,000.00 October 1st, 1961.\t.x\t16,000.00 October 1st, 1962 .\t.x\t16,000.00 \t\t17,000.00 October 1st, 1964\t\t2,500.00 October 1st, 1965\t\t2,500.00 October 1st, 1966\t\t3,000.00 October 1st, 1967\t\t3,000.00 October 1st, 1968\t\t3,500.00 October 1st, 1969\t\t3,500.00 October 1st, 1970\t\t3,500.00 October 1st, 1971\t\t4,000.00 October 1st, 1972\t\t4,000.00 October 1st, 1973\t\t4,500.00 October 1st, 1974\t\t5,000.00 October 1st, 1975\t\t5,000.00 October 1st, 1976\t\t5,000.00 October 1st, 1977____\t\t5,000.00 October 1st, 1978.\t\t5,000.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of S80,944.50 granted by the Provincial Secretary and payable in five instalments $16,188.90 each from 1959 to 1963 inclusively, will be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Terrebonne, county of Terrebonne.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior to October 1st,'' 1968 inclusively; after which date, the said bonds may, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, be redeemed' by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed 3588 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1968, Tome 90, N° 42 Province de Québec _ y Cité de Côte St-Luc (Comté de Montréal-Notre-Dame-de-Grâces) Avis public est par les présentes donné, que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, I.G.Wilcken, greffier, Hôtel-de-Ville, 8,100 Côte St-Luc, Comté de Montréal-Notre-Dame-de-Grâces, jusqu'à 8.00 heures p.m., lundi, 3 novembre 1958, pour l'achat de $651,000.00 d'obligations de la cité de Côte St-Luc, comté de Montréal-Notre-Dame-de-Grâces, datées du 1er décembre 1958 et remboursables par séries du 1er décembre 1959 au 1er décembre 1978 inclusivement avec intérêt à un taux non-inférieur à 4^%» n» supérieur à 5%% par année, payable semi-annuellement le 1er juin et le 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Les règlements numéros 276 \u2014 $73,900.00, égouts, trottoirs et chemins; 337 \u2014 $4,300.00, acquisition d'un lot; 344 \u2014 $4,700.00, acquisition d'un lot; 347 \u2014 $26,500.00 trottoirs et pavage; 348 \u2014$15,500.00, trottoirs et pavage; 356 \u2014 $329,000.00, construction d'un chemin; 362 \u2014 $4,000.00, acquisition d'un lot; 385 \u2014 $59,000.00, égouts; 395 \u2014 $76,000.00, égouts; et 400 \u2014 $59,000.00, égouts.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er décembre 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $661,000.00 \u2014 20 am Année Capital 1er décembre 1959.$21,000.00 1er décembre 1960.23,000.00 1er décembre 1961.25,000.00 1er décembre 1962 .25,000.00 1er décembre 1963.« .26,000.00 1er décembre 1964 .27,000.00 1er décembre 1965.28,000.00 1er décembre 1966.30,000.00 1er décembre 1967 .32,000.00 1er décembre 1968 .33,000.00 1er décembre 1969 .33,000.00 1er décembre 1970 .35,000.00 1er décembre 1971.37,000.00 1er décembre 1972 .37,000.00 Province of Quebec City of Côte St.Luc (County of Montréal-Notre-Dame-de-Grâces) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned I.G.Wilcken, City-Clerk, City Hall, 8,100 Côte St.Luc Road, Côte St.Luc, county of Montreal-Notre-Dame-de-Grâce, until 8.00 o'clock p.m., Monday, November 3rd, 1958, for the purchase of an -issue of $651,000.00 of bonds of the city of Côte St.Luc, county of Montreal-Notre-Dame-de-Grâce, dated December 1st, 1958 and redeemable serially from December 1st, 1959 to December 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate not less than 4j^% nor more than bx/>% per annum, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws numbers 276 \u2014 $73,900.00, sewers, sidewalks and roadways; 337 \u2014 $4,300.00, acquisition of lot; 344 \u2014 $4,700.00, acquisition of lot; 347 \u2014 $26,500.00, sidewalks and pavement; 348 \u2014 $15,500.00, sidewalks and pavement; 356 \u2014 $329,000.00, construction of road; 362 \u2014 $4,000.00, acquisition of lot; 385 \u2014 $59,000.00, sewers; 395 \u2014 $76,000.00, sewers; and 400 \u2014 $59,000.00, sewers.For the purposes of awarding the issue only, computation of interest will be made as from December 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014$651,000.00 \u201420 years Year Capital December 1st, 1959.$21,000.00 December 1st, 1960.23,000.00 December 1st, 1961.25,000.00 December 1st, 1962 .25,000.00 December 1st, 1963 .26,000.00 December 1st, 1964.\".27,000.00 December 1st, 1965 .28,000.00 December 1st, 1966 .30,000.00 December 1st, 1967 .32,000.00 December 1st, 1968 .33,000.00 December 1st, 1969 .33,000.00 December 1st, 1970.35,000.00 December 1st, 1971.37,000.00 December 1st, 1972 .37,000.00 les plus éloignées et les numéros les plus élevés, will be called for payment in reverse order o' maturity and serial number.Chaque soumission devra être accompagnée Each tender must be accompanied by a certi-d'un chèque accepté égal à 1% du montant de fied cheque equal to 1% of the amount of-the l'emprunt et devra spécifier si le prix offert present issue and must specify whether interest comprend ou ne comprend pas les intérêts courus accrued on the bonds to the date of their delivery sur les obligations au moment de leur livraison, is included or'not in the price of the tender.Les soumissions seront ouvertes et considérées The tenders will be opened and considered à une séance des commissaires d'écoles qui sera at a meeting of the school commissioners to be tenue mercredi, le 5 novembre 1958, à 8.00 du held on Wednesday, November 5, 1958, at soir, à l'école Boileau, Saint-François-de-Sales, 8.00 o'clock p.m., at the Boileau School, Saint-comté de Laval.François-de-Sales, county of Laval.Les commissaires d'écoles se réservent le droit The school commissioners are not bound to de n'accepter ni la plus haute ni aucune des accept the highest or any of the tenders, soumissions.Saint-François-de-Sales (Comté de Laval), ce Saint-François-de-Sales (County of Laval), 15 octobre 1958.this October 15, 1958.Le Secrétaire-trésorier, LUCIEN CARTIER, LUCIEN CARTIER.Secretary-Treasurer.Adresse postale: Post Office Address: 6830 Boulevard des Mille-Iles, 6830 Mille-Iles Boulevard, Saint-François-de-Sales (Laval), P.Q.Saint-François-de-Sales (Laval), P.Q.Tél.: NOrmandie 6-8034.48853-o Tel.: NOrmandie 6-8034.48853 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 18th, 1968, Vol.90, No.3589 1er décembre 1973.37,000.00 1er décembre 1974.37,000.00 1er décembre 1975 .38,000.00 1er décembre 1976 .41,000.00 1er décembre 1977 .42,000.00 > 1er décembre 1978 .44,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Montréal.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec, de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, aussi bien qu'au\" siège social de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas remboursables par anticipation avant le 1er décembre 1968 inclusivement; après cette date lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; dependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du Conseil qui sera tenue lundi, 3 novembre 1958 à 8.00 heures p.m., à l'Hôtel-de-Ville, 8,100 Chemin Côte St-Luc, Côté St-Luc, comté de Montréal-Notre-Damc-de-Grâces.Le Conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Côte St-Luc, (Comté de Mohtréal-Notre-Dame-de-Grûces), ce 16 octobre 1958.Le Greffier, I.G.WILCKEN.Hôtel-de-Ville, 8,100 Chemin Côte St-Luc, Côte St-Luc, (Montréal-N.-D.-G.), P.Q.Téléphone: HUnter 9-3847.48857 Province de Québec Village de St-Antoine-des-Laurentides (Comté de Terrebonne) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Lionel Nadon, secrétaire-trésorier, école St-Stanislas, St-Antoine-des-Laurentides, comté de Terrebonne, jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, le 3 novembre 1958, pour l'achat de $25,000.00 d'obligations du village de St-Antoine-des-Laurentides, comté de Terrebonne, datées du 1er décembre 1958 et remboursables par séries du 1er décembre 1959 au 1er décembre 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à ni supérieur à blA% par année, payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.\u2022 Règlement d'emprunt N° 7 \u2014 travaux d'aqueduc, réparations de rues, etc.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er décembre 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: December 1st, 1973 .37,000.00 December 1st, 1974 .37,000.00 December 1st, 1975.38,000.00 December 1st, 1976.41,000.00 December 1st, 1977.42,000.00 December 1st, 1978 .44,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Montreal.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the main office of the said bank in Toronto.The said bonds will not be redeemed by anticipation before December 1st, 1968 inclusively; after the latter date, the said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Monday, November 3rd, 1958, at 8.00 o'clock p.m., at the City Hall, 8,100 Côte St.Luc Road, Côte St.Luc, county of Montreal-Notre-Dame-de-Gr&ces.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Côte St.Luc, (County of Montreal-Notre-Damc-de-Grfice), this October 16, 1958.I.G.WILCKEN, City Clerk.City Hall, 8,100 Côte St.Luc Road, Côte St.Luc, (Montreal-N.-D.-G.).Telephone: HUnter 9-3847.48857-o Province of Quebec Village of St-Antoine-des-Laurentides (County of Terrebonne) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Lionel Nadon, Secretary-Treasurer, St-Stanislas school, St-Antoine-des-Laurentides, county of Terrebonne, until 8.00 o'clock p.m.Monday, November 3, 1958, for the purchase of $25,00Q.O0 of bonds of the village of St-Antoine-des-Laurentides, county of Terrebonne, dated December 1st, 1958 and redeemable serially from December 1st, 1959 to December 1st, 1978 inclusively, at a rate of not less than 4^% or more than 5J^% per year, payable semi-annually, on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law No.7 \u2014 waterworks operations, repairing of streets, etc.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from December 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 $25,000.00 \u2014 20 ans Table of redemption \u2014 $26,000.00 \u2014 20 years Année Capital Year Capital 1er décembre 1959.$1,000.00 December 1st, 1959.$1,000.00 1er décembre 1960.1,000.00 December 1st, 1960.1,000.00 3590 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 octobre 1958, Tome 90, N° 48 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1961.1,000.00 1962.f'000.00 1963.1,000.00 1964.1,000.00 1965.1,000.00 1966.1,000.00 1967.1,000.00 1968.1,000.00 1969.1,500.00 1970.1.500.00 1971.1.500.00 1972.1,500.00 1973.1.500.00 1974.1.500.00 1975.1,500.00 1976.1.500.00 1977.1,500.00 1978.1,500.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-.ltrôme, comté de'Terrebonne.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er décembre -1908 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941.être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra specifier si le prix offert com- {irend ou ne comprend pas les intérêts courus sur es obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 3 novembre 1958, à 8.00 heures du soir, à l'école St-Stanislas, St-Antoine-des-1 au rent ides, comté de Terrebonne.Le conseil se réserve le droit «le n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Antoine-des-Laurenti«les, (Comté «le Terre-bonne), ce 16 octobre 1958.Le Secrétaire-trésorier.LIONEL NADON.Adresse postale: 700, Sème avenue, St-Jérôme, (Terrebonne), P.Q., Téléphone: GÉnéral 2-7559 à St-Jérôme.48858-o Province de Québec Village de Saint-Jean-Eudes .(Comté de Chicoutimi) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, J.-A.Bittner, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, Saint-Jean-Eudes, comté «le Chicoutimi, jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, le 3 novembre 1958 pour l'achat de §53,000.00 d'obligations du village de Saint-Jean-Eudes, comté de Chicoutimi, datées du 1er octobre 1958 et remboursables par séries du 1er octobre 1959 au 1er octobre 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4^% ni supérieur à 5^% par année, payable semi-annuelle-ment les 1er avril et 1er octobre de chaque December 1st, 1961.1,000.00 December 1st, 1962.1,000.00 December 1st, 1963.1,000.00 December 1st, 1964.1,000.00 December 1 st, 1965.1,000.00 December 1 st, 1966.1,000.00 December 1 st, 1967.1,000.00 December 1st, 1968.1,000.00 December 1st, 1969.1,500.00 December 1st, 1970.1,500.00 December 1 st.1971.1,500.00 December 1st, 1972.1,500.00 December 1st, 1973.1,500.00 December 1 st, 1974.1,500.00 December 1 st, 1975.1,500.00 December 1st, 1976.1,500.00 December 1 st, 1977.1,500.00 December 1 st, 1978.1,500.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certifie»! cheque payable at par at St.Jérôme, county of Terrebonne.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior to December 1st, 1968 inclusively; after which date, the said bonds may, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, be redeemed by anticipation, in whole, or in part, at par, at any interest maturity date; however, in 'case of partial re
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.