Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 20 juin 1964, samedi 20 (no 25)
[" «)68 année vol.96 N° 25 3277 Uiette officielle de fuéèec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE OucIm'c.samedi 20 juin 1961 Règlements l' Adresser tout* correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Hôtel «lu Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielle*.Lorsque celle-ci est enrayée dans une BClllc langue, la traduction en esl faite aux frais «les intéressés, d'après le tarif officiel.Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le COÛ1 des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, disque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.ô° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.as «les avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième si celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre «o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduct^n- Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.VImprimeur de la Reine, Rom Lkfkbvke.Hôtel du Gouvernement, Québec.5 mai 1962.5177 \u2014 l-52-o Lettres patentes Abboud Construction Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du lie jour de mai 1964.constituant en corporation: Holland Biais, Raymond Bernier, avocats, et Georges Paulin, comptable, tous trois de 1595, rue Saint-Hubert, Montréul, pour les objets suivants* Exercer le commerce de constructeur et d'entrepreneur général dans la construction, sous le nom «le « Abboud Construction Limited », avec un capital total de $20,000, divisé en 600 actions ordinaires d'une valeur au puir de $10 chacune et 1,400 actions privilégiées d'une valeur au puir de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 1 le jour de mai 1964.Le Sous-xcerétaire de la province, Raymond Douville.6969 2001-64 Accessoires de camping mobile ltee Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 13e jour de mai 1964, constituant en corporation: Wilfrid Boulin, entrepreneur, Marcelline Drapeau, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Wilfrid Boulin, tous deux de 8886, boul.Gouin, est, Montréal, et Yolande I.ann, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens de René (ioupil, 8081, St-Dominique, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de marchandises et articles de sport, sous le nom de « Accessoires de camping mobile ltée », avec un capital total de $40,000, Advertising, Rates, Subscriptions, etc.Fiist insertion: 30 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents per agate line, for etch version.Tubular mal ter (lists of names, figures, etc.) at doub&B rate.Translation: $1.per 100 words.Single copies: 40 cents each.Slips: $1.50 per dozen.Subscriptions: $10.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have tlic following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the fiist insertion; the third to the number of insert ions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but once are Hollowed only by our document number.Rom Llfkbvhk, Queen's Printer.Parliament Buildings.Quebec.May 5.1962.5177 \u2014 l-52-o Letters Patent Abboud Construction Limited Notice is hereby given that under Barl I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Rolland Biais, Raymond Bernier, lawyers, and Georges Boulin, accountant, all three of 1595 St-Hubert Street.Montreal, for the following purposes: To carry on the business of constructor and general contractor for the construction, under the name of \"Abboud Construction Limited\", with a total capital stock of $20,000, divided into 600 common shares of the par value of $10 each and 1,400 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(\u2022iven at the office of the Provincial Secretary, this 11th day of May, 196-1.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969-o 2001-61 Accessoires de camping mobile ltée Notice is hereby given that under Bart I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 13th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Wilfrid Boulin, contractor, Marcelline Drapeau, housekeeper, wife contractually separate as to property of the said Wilfrid Boulin, both of 3885 Gouin Blvd., East, Montreal, and Yolande Larin.housekeeper, wife contractually separate as to property of René Coupil, 803J St-Dominiquc, Montreal, for the following purposes: To carry on business dealing in merchandise and articles of sport, undc.the name of \"Accessoires de camping mobile ltée\", with a total capi- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 1904, Vol.96, No.g 3279 divisé en 20 actions ordinaires onne.Donné au hureau du secretaire de la province, ce 13e jour de mai 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dor ville.6960-o 1513-64 Admiral Ahimimini Sales Corp.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a rte accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du So jour «le mai 1964, constituant en corporation: Roll in (iallay.6196.rue Hudson, Joel A.Pinsky, 4597, rue Oxford, tous «leux avocats, et Isohel Nicholson, secrétaire, fille majeure, 3661, nie Sainte-Famille, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Kxercer le coramcrcc d'une compagnie de placements, sous le nom de « Admiral Aluminum Sales Corp.», avec un capital total «le $15,000, divisé en 15.000 actions or«linaires de $1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 8e jour de mai 1904.1a\" Sous-secrétaire de la province, Raymond Dor ville.6069 2073-64 Allan Distributors i'-o.Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du le jour de mai 1964, constituant en corporation: Robert Val«>vic, marchand.7926, Berman, Montréal, Marilyn Marcovitch, ménagère, épou-se séparée de corps et «le biens de Stanley Bernstein, 7460, Kingsley, (Y>te-Saint-Luc, et Catherine Ewart, secrétaire, fille majeure, 2015, rue Drummond, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'un établissement de détail, sous le nom de « Allan Distributors Co.Ltd.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires «le $1 chacune et \u2022i.000 actions privilégiées «le $10 chacune.I .c siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 4e jour «le mai 1964.1a Souk-secrétaire de la province, Raymond Douville.f Terrebonne.(\u2022iven at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of May, 1964.Raymond Don ville, Assistant Secretary of the I'rotnuce.6969 1513-64 Admirul Aluminum Sales Corp, Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 8th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Rollin Gal-lay, 6196 Hudson Street.Joel A.Pinsky, 4597 Oxford Street, both advocates, and Isobel Nicholson, secretary, spinster of the full age of majority, 3661 Ste-Famille Street, all three of Montreal, for the following purpose*: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Admiral Aluminum Sales Corp.\", with a total capital stock of $15,000, divided into 15,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 8th day of May, 1964.Raymond Den'ville, Assistant Secretary of the Province.6969-c) 2073-64.Allan Distributors Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, hearing date the 4th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Oovernor of the Province of Quebec, incorporating: Robert Valovic.merchant.7926 Berman.Montreal, Marilyn Marcovitch, housewife, wife separate as to bed and board of Stanley Bernstein, 7460 Kingsley, Côte-St-Luc, and Catherine Ewart, secretary, fille majeure, 2015 Drummond Street, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a retail establishment, under the name of \"Allan Distributors Co.Ltd.\", with a total capital stock of $-10,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will l>e at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of May.1964.Raymond Dor ville, Assistant Secretary of the I'rorince.6969-o 1976-64 Allyson & Raymond Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 2Sth day of April, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Michael (iarber, q.c, 4338 Montrose Avenue, West-mount, Jacob Harold Blumeustein, q.c, 4815 Queen Mary Road, Montreal.Harry Yohalen (iarber, 3235 Ridgewood Avenue.Montreal, all three advocates, and Irene Rubin, secretary, fille majeure, 5552 Snowdon Avenue, Montreal, for the following purposes: '._ \\ g ssj 3280 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin W4, OU' année.No 80 Bteecer !«\u2022 commerce «l'un certain immeuble, sous I»' nom de « Allyson & Raymond Ltd.», aver un capital total de $75,000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune cl 7,100 actions privilégiées de $10 chacune.Iuverneur de la province de Québec, eial «le la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 13e jour «le mai 1901.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond DouviLLB.G909 2066-64 L'Association des propriétaires de taxis de Si-Rom iiaid inc.Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie de la Ia>\\ des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 5e jour de mai 1964, constituant en corporation sans capital-actions: Irenée Roberge, propriétaire «le taxi, 1094, Commerciale, St-Romuald, Arthur Demers, propriétaire «le taxi, 19, rue Sax, St-Romuald, et Jean-(iuy Nolet, To deal with a certain immoveable property' umler the name of \"Allyson & Rn.wnoud Ltd.' with a total capital stock «>f $75,000, divided into 100 common shares of $10 each and 7,400 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Acton Vale, judicial district «»f st-Hyacinthe.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 38th day of April.1964.Raymond Doi vii.i.k, Assistant Secretari/ of the 1'rovince.6969-e 1957-64 Ambcrcbe inc.Notice is hereby given that umler l'art I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 13th «lay «>f May, 1064, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quehc«\", incorporating: Pierre Chèvrefils, a«lvocate.I'.-Denis Laberge, SJOCOUnt-attt, both of Ste-Marline.and Yves Ainplcmmi.advocate, Beauharnois, for the following purposes: To carry on business dealing in real estate, construction, investment and holding company, umler the name of \"Amberche inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of $5 each ami into 7,000 preferred shares of a nominal value of $5 each.The head office «>f the company will be at Ste-Martine, county of Chateauguay, judicial district of Bcauharimis.Given at the office «>f the Provincial Secretarv.this 13th day of May, 1904.Raymond Dol'villk, Assistant Secretary of the Province.0909 214.\")-» il Arrow Construction Inc.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 13th day of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor «»f the Province of Quebec, incorporating: Leo Etosents- veig, 4805 Circle Road, Montreal, Stanley Taviss, 7115 Fielding, Montreal, and William Levitt, 5020 St.Kevin, Montreal, all three advocates, f«>r the following purposes: To carry on the business of a construction, realty and investment company, umler the name of \"Arrow Construction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 300 preferred shares «>f $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district «>f Montreal.(\u2022iven at the office of the Provincial Secretarv, this 13th day of May, 1904.Raymond Doi;vii.i.k, Assistant Secretary of the Province.0909-o 2056-64 L'Association des propriétaires de taxis de St-Romuald inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without, share capital: Irenée Roberge, taxi owner, 1094 Commerciale, St-Romuald, Arthur Demers, taxi owner, 19 Sax St., St-Romuald, and Jean-Guy Nolet, taxi owner, 36 QUEBEC OFFICIAL OMETTE, June 80, 1964, Vol.00, No.Ha 3281 propriétaire de taxi, 89, St-.lcan-Haptiste, St-Kormiald, pour les objets suivants: Défendre et promouvoir le commerce de transport par taxi ainsi qu'offrir au public un service de transport sûr et efficace dans la ville de St-Romuald et les municipalités environnantes, sous le nom «le « L'Association «les propriétaires de taxis de St-Rornuald inc.V.Le siège social de la «-orporation sera 10, rue de l'Eglise, St-Romuald, district judiciaire «le Québec Donné au bureau du s«crctaire de la province.ce 5e jour de mai 1964./.c Soux-xeerefaire de la jirorince, Raymond Douvilub.6969-0 1987-64 St-.Ican-Baptiste.St-Romuald, for the following purposes: To défend and promote the business of transportation by taxi as well as offering to the public a safe and efficient transportation service in the town of Sl-ltomuald ami the neighboring municipalities, under the name of \"L'Association des propriétaire] «le taxis f May, 1964.Raymond Douvims, Axxixtaiil Secreturtj of the Province.0909 1987-64 L'Association des propriétaires du Vieux .Montréal inc.The Association of Property Owners of Old Montreal Inc.Avis est dottné1 qu'en vertu «le la troisième partie «le la Loi d«is compagnies de Québec, il a «'\u2022té accordé, par le lieutenant-g«»u\\ernciir «le la province «le Québec, «les lettres patentes, «m date du 12e jour de mai 1964, constituant «-il corporation sans capital-actions: Leopold Dernier, marchand, 46, Ha/.elwood.Outremont, Raoul Remuer, marchaml, 1203.boni.Mont-Royal, Outremont, Jean-Paul Parent.SVOCat, 758.18e Avenue, Potnte-aux-Trembles, Barry Por- teous, marchand, 19, avenue Willow, Westmount, Aiirélien N'oël, comptable agréé.200, avenue Outremont, Outremont, R.W.Gall, courtier en assurance, 082, 39e Avenue, Lachine, Gérard bortie.industriel.2931, avenue Kendall, Montréal, Peter S.Wise, comptable agrc;é.5900, McDonahl, Hampstea«l, et Joseph S.Drazin.courtier en immeubles, 0722, rue de Vimy, Montrt'al.pour les objets suivants: Coopérer avec la Commission des monuments historiques «le la Province «le Québec, de la ( 'ommission Viger de la cité «le Montréal pour la conservation, la rénovation et l'embellissement du Vieux Montréal, sous le nom de « L'Association des propriétaires «lu Vieux Montréal inc.\u2014 The Association of Property Owners of Old Montreal Inc.».Le montant auquel sont limités les biens immo-biliers que la corporation peut acquérir et posséder, est «le 110,000.Le siège social «le la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 12e jour «le mai 19(54.Le Soux-xeerétaire de la province, Raymond Douvillb.6969-0 1775-04 Au Sablonne! de Jonquière ltée Avis est donné «m'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé* par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en date «lu 30e jour «l'avril 1904, constituant en corporation: Y von Tremblay, restaurateur, 270A, St-Dominique, Alida Tremblay et Yvette Tremblay, ces deux dernières commis, filles majeures, «le 204.St-Dominique, tous trois «le Jonquière, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom «le «x Au Sablonnet «le Jonquière ltée », avec un capital total «le $40.000.divisé en 2,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 1.500 actions privilégiées de $10 chacune.L'Association des propriétaires du Vieux Montréal inc.The Association of Property Owners of Old Montreal Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act.letters patent.bearing date the 12th «lay of May.1904, have bean issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, t«> incorporate as a corporation without share capital: Leopold Bcrnier, merchant, 48 Hnaehvood, Outremont, Raoul Bernier.merchant, 1203 Mount Royal Blvd., Outremont, Jean-Paul Parent, advocate, 758, 18th Ave., P«>inte-aux-Trcmbles, Barry Porteous, merchant.19 Willow Ave., Westmount, Auré- lien Noel, chartered accountant, 266 Outremont Ave.Outremont.R.W.Gall, insurance broker, 082.39th Ave., Lachine.(îcrard Lortie, industrialist, 2931 Kendall Ave., Montreal.Peter S.Wise, chartered accountant, 5900 McDonahl, Hempstead, and Joseph S.Dia/.in, real estate broker, 0722 de Vimy St.Montreal, for the following purposes: To cooperate with the Historic Monuments Commission of the Province of Quebec, with the Viger Commission of the city of Montreal, for the preservation, renovation and beautifying of Old Montreal, under the name of \"L'Association des propriétaires «lu Vieux Montreal inc.\u2014 The Association of Property Owners of Old Montreal Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is t«> be limited, is $10.000.The head office of the corporation will l>e at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 12th .lay of May.1904.Raymond Dorvii.i.k.Assistant Secretary of the Province.6969 1775-64 Au Sablonnet de Jonquière ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «latc the 30th day f April.1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Y von Tremblay, restaurateur.270A.St-Dominique, Alida Tremblay and Yvette Tremhlay.the latter two clerks, filles majeures, of 204 St-I)«>mini«|ue, all three of Jonquière, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Au Sablonnet «le Jompiière ltée\".with a total capital stock of $40.000.divided into 2.500 common shares of $10 each ami into 1.500 preferred shares of $10 each. 3282 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, SO juin 1904, 96* année.No g Le .siège social de la compagnie sera à Jonquière, district judiciuire de Chicoutimi.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour d'avril 1904.Le Sous-.swreluire de la province, Raymond DouVILLE.0909-o 770-04 K & K Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 8e jour de mai 1904, constituant en corporation: Gerald Freed, avocat, 1390.Carol Crescent, Chomedey, Kleanor Rosenthal.5200, avenue Grenier, Montréal, et Naomi Hugues-Hallett.3375, avenue Ridgcwood, Montréal, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Agir comme courtiers et agents de manufacturiers et transiger toutes sortes d'agences, sous le nom de « H & H Corporation », avec un capitul total de $20,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 150 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 271, avenue YVillowdale, Oui remont, «listrict ju«li-ciaire de Montrt'-al.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 8e jour de mai 19(54.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvili.k.0909 2003-04 lîari Importing Company Inc.Avis est «humé qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Quél>ec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 28e jour «l'avril 1904, constituant en corporation: Frank Ma/./.illi, importateur, 9107, avenue Esplanade, Montréal, Leon Jedeikin, avocat, 11, avenue Windsor, VVestmount, et Mark Abramouitz, avocat.5500.avenue Rose-dale, Côte-Saint-Luc, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le toutes sortes «le produits, articles et marchandises faits, en tout ou en partie, «le cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textile, verre et leurs sous-pr«xluits, et merceries, produits alimentaires, animaux, minéraux, pierres précieuses, liqueurs gazeuses, livres et périodiques, peintures, oeuvres «l'art, produits chimiques, produits de la terre, de la mer et de la foret, produits de béante, cosmétiques, articles de toilette et parfums, sous le nom de « Bari Importing Company Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $100 chacune.Ia' siège social de la compagnie sera 7417, rue Marquette, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 28e jour d'avril 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.6909 1S65-64 The head office of the company will be at Joiupiière, judicial district of Chicoutimi.Given at the 0008 of the Provincial Secretarv, this 30th .lay of April.1904.Raymond Douvii.i.k, Assistant Secretary of the Province.0909 776-64 It & H Corporation Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the St h day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of tin-Province of Quebec, incorporating: Gerald Freed, advocate, 1390 Carol Crescent, Chomc-dey, Eleanor Rosenthal.5200 Crenicr Avenue, Montreal, ami Naomi Hughes-IIallett.3375 Ridgewood Avenue.Montreal, the latter two secretaries, filles majeures, for the following purposes : To act as brokers and manufacturers' agent * and to transact all kinds of agency business, under the name of \"H & H Corporation\", with a total capital stock of $20,000, divided into 500 common shares of a par value of $10 each ami 150 preferred shares of a par value t>f $100 each.The head office «>f the company will l>e at 271 Willowdale Avenue.Outremont, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretarv.this 8th day of May.1964.Raymon d Douvillb, Assistant Secretary of hte Province.0909-o 2063-64 Bari Importing Company Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 28th day of April, 1964, have been issued by the Lieutenant-Coventor of the Province of Quebec, incorporating: Frank Ma/./.illi.importer, 9107 Esplanade Avenue.Montreal, Ix.*on Jedeikin, advocate, 11 Windsor Avenue, Westmount, ami Mark Abranuiwitz.advocate, 5600 Rosedale Avenue, ('Ate-St-Luc.for the following purposes: To deal in all kinds of products, articles and merchandise made, in whole or in part, of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by-products of same, and in haberdashery, ftxxl products, animals, minerals, precious stones, soft drinks, books and periodicals, paintings, works of art, chemical products, land, sea and forest products, beauty products, cosmetics, toilet articles ami perfumes, umler the name of \"Bari Importing Company Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 200 common shares of the par value of $100 each ami 200 preferred shares «)f tin-par value of WOO each.The head office of the company will be at 7417 Marquette Street.Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretarv.this 28th day of April, 1904.Raymond Doi'villk, Assistant Secretary of the Province.6969-0 1805-04 Cyrille Beaudry inc.Cyrille Beaudry inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 1964, Vol.96, No.25 8283 été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 15e jour de mai 1964, constituant en corporation: Cyrille Beaudry, commerçant de bois, Bertrand Beaudry, vendeur, et Camille Beaudry, camionneur, tous trois de La Guadeloupe, pour les objets suivants: Industrie et commerce du bois, sous le nom de « Cyrille Beaudry ine.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à La (iuadeloupe, comté de Frontenac, district judiciaire de Beauce.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 15e jour de mai 1904.lœ Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvilli:.6969-0 2180-64 Beaudry & Lacoste inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a \u2022'\u2022té accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 12e jour «le mai 1904, constituant en corporation: Reginald Beaudry, Guy Lacoste et Jean-Louis Lacoste, tous trois camionneurs, «le St-Alexandrc, comté dTberville, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «le transport, sous le nom de « Beaudry & Lacoste inc.», avec un capital total «le $200,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à St-Alexandre, district judiciaire «l'H>erville.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 12e jour «le mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.0969-o 2068-64 Bee Sportswear Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 0e jour «l'avril 1904, constituant en corporation: Boris (i armai m.avocat, 3523, bon!.Saint-Laurent.Frank Kishner, comptable, 4911, Van Horne, tous deux de Montréal, et Guy Coulombc, gérant, 9081, 13e Avenue, Saint-Michel, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le vêtements, sous le nom de « Bec Sportswear Ltd.», avec un capital total de $1,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune.la- siège social de la compagnie sera à M out real, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 6e jour d'avril 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.6969 2039-64 bearing «late the 5th «lay of May, 1904, bave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Cyrille Beaudry, wood «lealer, Bertrand Beaudry, salesman, and Camille Beaudry, trucker, all three of La Guadeloupe, for the following purposes: To carry on an industry ami business dealing in wood, under the name «>f \"Cyrille Beaudry inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The bend office of the company will be at La Guadeloupe, county of Frontenac, judicial district of Beauce.(îiven at the office of the Provincial Secretary, this 15th «lay of May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.0909 2180-04 Beaudry & Lacoste ine.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 12th day of May, 19(54, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Reginald Beaudry, Guy Lacoste, ami Jean-Louis Lacoste, all three truckers, of St-Alexandre, county of Iberville, for the following purposes: To carry on business as a transportation company, under the name of \"Beaudry & & Lacoste inc.\", with a total capital stock of $200,000.divided into 2,000 common shares of $100 each.The head office of the company will be at St-Alcxandre.judicial district of Iberville.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 12th day of May, 1964.Raymon d Douvillk, Assistant Secretary of the Province.0909 20t>8-64 Bee Sportswear Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 6th «lay of April, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Boris Gar-maise, lawyer, 3523 St.Lawrence Blvd., Frank Kishner, accountant, 4911 Van Home, both of Montreal, an«l Guy Coulombe, manager, 9081.13th Avenue, St-Michel, for the following purposes : To deal in clothing, under the name of \"Bee Sportswear Ltd.\", with a total capital stock of $1,000, divided into 1,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this Oth day of April, 1964.RaYMON i) dou villk, Assistant Secretary of the Province.09G9-o 2039-04 Berkshire Sportswear Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 6e jour de mai 1904, constituant en corporation: Albert Malouf, c.r., 1100, Marlboro, Berkshire Sportswear Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the Oth «lay of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Albert Malouf, Q.c, 1100 Marlboro.Mount Royal, Bruno 3284 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SO juin ldtiJ,, M* année.No 25 Mont Royal.Bruno Paieras, 11818, Frigon, Montréal.Yvan Maeerola, 2090, place Etienne Brûlé, Montréal, et ('.James Galileo, «959.Stuart.Montréal, tous quatre avocats, pour les objets suivants : Faire le commerce d'articles vestimentaires, sous le nom de « Berkshire Sportswear Limited >».avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et KM) actions privilégiées de $100 chacune.I,c siège social de la compagnie sera 0880, rue Clark.Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 6e jour de mai 1964 1a Stius-stcrcluirc di la prminec.Raymond Douvillk.6060 2028-64 Pntcras, 11818 Frigon, Montreal, Yvan Maocrola.2000 Eticnue-Brulé Place, Montreal, and C.James Galileo, 6080 Stuart, Montreal, all four advocatea, for the following purposes: To ileal in wearing apparel, umler the name of \"Berkshire Sportswear Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided Into 300 common shares of Slot) each and l(K) preferred shares of 9100 each.The head oliice of the company will he at 9880 Clark Street, Montreal, judicial district «>f Montreal Given at the office of the Provincial Secretary, this 6th day of May, 1901.Raymond Dou ville, Assistant Seen tarn f May, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor f hotel, tavern, public bouse and/or restaurant or any combination thereof, under the name of \"Cat's Den Inc.\", with a capital divided into 1,000 sharea without nominal or par value.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office «>f the Provincial Secretary, this 12th day of May.1964.Raymond Douvillk, Assista ut Secretary of the Province.6969-0 1968-64 (Centre agricole d'Abitibi inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.tetters patent, bearing «late the 12th «lay of May.1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Léo McNeil, consignee, St-Marc-de-Figuery, André Lambert, consignee.Amos, and Lorraine Parent, stenographer, fille majeure.Val-d'Or, for the following purposes: To carry on business dealing in motors, machines, their parts ami accessories, umler the name of \"Centre agricole d'Abitibi inc.\".with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office «>f the company will be at Amos, judicial district of Abitibi.Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th «lay of May.1904.Raymom d Douvillk, Assistant Secretary of the Province.0909 2014-64 Centre de couture Universel inc.Universal Sewing Centre Inc.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 0th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Fernando Begin, merchant, 15 St-Pierre Blvd.Notre-Dame- property of Laurent Auger.1830 Vitré St.Quebec, ami Paul H.Martel, accountant.1287 Fontenay Ave., Ste-Foy, f*»r the following purposes: To carry on business in the industry, sale, maintenance ami repairs t«> all sewing machines, umler the name of \"Centre de couture Universel inc.\u2014Universal Sewing Centre Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of a par value of $100 each.The head office «>f the company will be at 975.3rd Ave., Quebec, judicial district of Quebec Given at the office of the Provincial Secretary, this 0th «lay of May, 1964.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.6969 2037-64 3280 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 1964, .%\" année.So 25 Centre professionnel de Verdun ltée Avis est flouiu- qu'on vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province île Québec, «les lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1064, constituant en corporation: Dr Georges Bélanger, 149, «le Champagne, Longueuil, Dr P.-Marcel Bélanger, 4395, Verdun, Verdun, et Dr Bertrand Dumais, 55, Church, Verdun, tous trois mf the Province of Quebec, incorporating: Dr.Georges Bélanger, 149 «le Champagne, Longueuil, Dr.P.Marcel Bélanger, 4395 Verdun, Verdun, and Dr.Bertrand Dumais, 55 Church, Verdun, all three physicians-surgeons, for the following purposes: To operate one or more professional centers for physicians-surgeons or for any other profession ami occupation, umler the name of \"Centre professionnel «le Verdun ltée\", with a t«>tal capital stock of $300,000, divided into 1,200 common shares of $100 each ami into 18,000 preferred shares «>f $10 each.The head office «>f the company will be al Verdun, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day «»f April, 1904.Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.6060 1800-01 Centre social et sportif du lac Simon inc.Notice is hereby given that umler Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corpora tion without share capital: André Lamalice.agent-salesman, Thérèse Aubin, secretary, fille majeure, both of 585 «lu Verger, and Guy Aubin, builder, 575 «lu Verger, all three of Duvernay.for the following purposes: To establish and direct a social ami sports club, under the name of \"Centre social et sport it «lu lac Simon inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $20,000.The head office of the corporation will be at ChénéviUe, judicial district of Hull.Given at the office of the Provincial Secretary, this 5th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969 1917-01 Château neuf Restaurant Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la I*oi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-g«>uverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du 27e jour d'avril 1964, constituant en corporation: Ezra l.eit h man.ch., Sidney Leithman et Harvey Varosky.tous trois avocats, «le 1255, Carré Philippe, Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce «le restaurateurs, sous le nom «le « Châteauneuf Restaurant Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires «le $100 chacune et 200 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social de la compaguie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 27e jour d'avril 1964, Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douviixk.6969 1955-64 Châteauneuf 'Restaurant Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of April, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Ezra Leith-man, q.c, Sidney Lcithman and Harvey Yarosky.all three advocates, of 1255 Phillips Square, Montreal, for the following purposes: To carry «>n business as restaurateurs, under the name of \"Châteauneuf Restaurant Inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares «>f $100 each ami 200 preferred shares of $100 each.The bead office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of April, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969-o 1955-64 QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, June 20, 1904, Vol.90, So.i» 3287 La Cie de plomberie et chauffage Paul Smith inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 29e JOUf «l'avril 1964, constituant en corporation: Georges Bilcdeau, c.R., 4000, boul.Gouin, est, Nlontréal-Nord, Bernard Hilodeau, 1134, Melrose, Montréal, tous deux avocats, et l'aul Smith, plombier, 904.rue Heaudoin, Jacques-Cartier, pour les objets suivants: Exercer le «'ommerce d'entrepreneurs en plomberie, chauffage et réfrigération, sous le nom «le « La Cie de plomberie et chauffage Paul Smith inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 904.Heaudoin, Jacqucs-( 'artier, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 29e jour d'avril 1964.Le Sous-secrétaire de la province, KaïMiim) Doi villk.6969-0 1521-64 Commercial Kitchen Services Limited Avis est donné qu'an vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accor«lé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentas, en date 'lu 6e jour de mai 1964, constituant en corporation: Gisèle Maguer, 432, rue Higaud, app.10, Montréal.Nathalie Mosier, 3425, avenue Ridgc-wood, Montréal, tontes deux secrétaires, célibataires, et llaykuzun Sumbulian.étudiant en droit.1255, Sherwood Crescent, app.225.Mont Royal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le marchands d'articles \u2022 le cuisine et de quincaillerie, sous le nom de \u2022Commercial Kitchen Services Limited», avec un capital total «le $40,000, divisé en 50 actions ordinaires «le $100 chacune et 350 actions privileges de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce Oe jour «le mai 1964.1a Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.6969 1911-64 Como inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a ¦¦té aceonlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 30e jour «l'avril 1904.constituant en corporation: Jean T.Vien.avocat, 3445.côte «les Neiges, Montréal, Micheline I.alande, secretaire, épouse séparée «le biens «le Guy Leduc, 8102, boul.Viau, St-Léonard, et Christine Diamond, secrétaire, 224, boul.St-Joseph, est.M oui rêal.pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «le placements.mmis le nom «le « Como inc.».avec un capital total «le $40,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et en 3,950 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 230, rue Orsalie, Beloeil, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 30e jour d'avril 1964.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.6969-0 1915-64 La Cie de plomberie et chauffage Paul Smith inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th «lay of April, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Georges Bilodeau, q.c, 4000 Gouin Blvd.East, Montreal-North, Bernard Bilo«li>au, 4434 Melrose, Mont-veal, both advocates, and Paul Smith, plumber, 904 Beaudoin St., Jactjues-Cartier, for the following purposes: To carry on business as contractors in plumbing, heating ami refrigeration, umler the name of \"La Cie de plomberie et chauffage Paul Smith inc.\", with a total capital stock «>f $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 964 Beaudoin, Jacf the company will be at 6010 Chambly Road, St-Hubert, judicial district «>f Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th «lay «»f May, 1904.Raymond Douvillb, Assistant Secretary of the Province.6969 2093-64 La Compagnie '\"Valnia\" lté«' Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th «lay of May.1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating' Philemon Lavoie, business agent, Bertrand (iladu, office clerk, ami Fernande Bourgoin.secretary, all three of Mont-Joli, for the following purposes: To breed ami deal generally in all kinds «»f animals and especially animals destined for butchery, under the name of \"La Compagnie \"\\ alma\" ltée\", with a total capital stock of $12.000, ilivided into 120 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Ste Angclc-«|e Méru-i.judicial district of Ri-mouski.Given at the office of the Provincial Secretary, tins 1th «lay of May.1904.Raymond Douvillb, Assistant Secretary of the Province.6969 1922-64 Contessa Hosiery Ltd.Notice is hereby given that under Part i of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 6th «lay of May.1904.have been issued by the Lieutenant-Governor «jf the Province of Quebec, incorporating: Mario Markic.manufacturer, Stitiô Wiseman Avenue, Montreal, Ludwig Loncar, mechanic, 3393.43rd Street, St-Michel, and Kalman Samuels, advocate, 1155 Dorchester West, Suite 3420, Montreal, for the following purposes: To deal in hosiery and ladies' wearing apparel, under the name of \"Contessa Hosiery Ltd.\", with a total capital stock of $20.000.\" divided into 150 common shares of $100 each ami ô0 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at llôô Dorchester Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 0th day of May.1904.Raymond Douvillb, Assistant Secretary of the Province.ii909-o 2047-64 Corpin liée Notice is hereby given that umler Part I of the «Québec Companies Act, letters patent, bearing date the Oth day of May.1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Fernand 8290 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 20 juin 1964, 90' année, So 25 Mon: Fernaml Sirois.comptable agréé.Si Nicolas.conté de Lévis, René Guny, homme d'affaires, Pointc-au- Pic, comté «h\" Charlevoix, , f the Provincial Secretary, this oth dayiof May.1964, Raymond DorviLLK.Assistant Secretary of the Province.0009 2025-64 La Corporation de développement Continental ltée Continental Development Corporation Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des Compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieuenant-gouverneur de la provuH'e de Québec, «les lettres patentes, en date du 20c jour «l'avril 1004.constituant en corporation: Gilles Lespérance, constructeur.2750.rue Bruxelles.Théo K.L'Espérance, ingénieur professionnel.8045, rue Tellicr.et Horace Lespérance.rentier.6080, rue Adam, tous trois «le Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «l'immcubles, de construction «'t «l«* placements, sous le nom de « La Corporation «le développement Continental ltée Continental Development Corporation Ltd.».avec un capital total «le $\".0.000, divisé en 5,000 actions ordinaires de S\") chacune et en 5.000 actions privilégiées «le $5 chacune.Le siège social «le la compagnie sera S045, rue Tellier, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 20e jour «l'avril 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dor ville.0909-o 5089-63 La Corporation «le développement Continental ltée Continental Development Corporation Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 20th f May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jonathan J.Robinson, advocate, 64 Belvedere Road, West-mount, Theodore H.Shapiro, advocate, 5175 côte St-Luc Road.Montreal, and Marcia Shetzcn.secretary, fille majeure, 2705 Kent Avenue, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Corsair Investments Ltd.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 1,000 common shares of $1 each.1,000 class \"A\" preferred shares of $1 each and 38,000 class \"B\" preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(liven at the office of the Provincial Secretary, this 6th day of May.1964.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.6969-q 2032-64 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.June 20.1964, Vol.M.So.g 3291 f'i'ilr construction inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la !/i «l«'s Compagnies «le Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late iln 6e jour «le niai 1064, constituant en corporation: remand (Y>té, menuisier, Bruno Desro-i liers, opérateur, tous «Jeux «le St-Flavien, comté .ir Lotoinière, et Jean-Paul Coté, menuisier, Joly, comté «le Lotbinière, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entre-preneurs généraux eu construction, sous le nom de «Côté construction inc.», avec un capital total «le 660,000, divisé en 600 actions ordinaires di 6100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Laurier-Mat ion, comté «le Lotbinière, district judiciaire de Québec Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce rte jour de mai 19rt4.I* Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Doi'villk.6960-e 2045-04 Country Club Casuals Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a ¦ ¦te accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en «late du Se jour «le mai 1964, Constituant en corporation: Manuel Shacter.4870, chemin Circle.Stanley Taviss, 7115, Fielding.Richard Gottlieb, 2960, Maplewood.et William Levitt.5020, St.Kevin, tous quatre avocats, de Montréal, pour ii - objets suivants: Exercer le commerce «le vêtements et «l'articles vestimentaires «le toutes sortes, sous le nom «le Country Club Casuals Inc.».avec un capital total «le $50.000.divisé en 5.000 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le $1 chacune et 15,000 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal.district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 5e jour «le mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillb.6969 1994-04 Dagenais et Desjardins ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première : m tie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a le accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du lie jour «le mai 1904, constituant en corporation: Marcel Dagenais, marchand, 11120, i'oul.(îouin, est, Richmond Desjardins, rentier, i 1590.boul.(îouin.est.tous deux de Quartier Kivière-des-Prairies, Montréal, et Paul-Emile Desjardins, marchand, 14, boul.St-Jean-Baptiste, l'ointe-aux-Tremhles, pour les objets suivants: Industrie et commerce du bois, sous le nom de \" Dagenais et Desjardins lt«'*e », avec un capital total «le $40.000.divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.IjC siège social de la compagnie sera 10740.iioul.Couin, est.Quartier Kivière-des-Prairies, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce lie jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.\u20221969-0 2036-64 Côté construction inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 6th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province f Quebec, incorporating: Fernand Côté, joim-r.Bruno Desrochers, operator, l>oth of St-Flavien, county of Lotbinière, and Jean-Paul Côté, joiner, Joly, county «>f Lotbinière.for the following purposes: To carry on business as builders arul general building contractors, under the name of \"Côté construction inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Laurier-Station, county of Lotbinière, judicial district of Quebec.(îiven at the office of the Provincial Secretarv, this 6th «lay of May.1964.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.6969 2045-64 Country Club Casuals Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 5th day of May.1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Manuel Shacter.4S70 Circle Road.Stanley Taviss.7115 Fielding.Richard Gottlieb, 2960 Maplewood, ami William Levitt.5020 St.Kevin, all four advocates, of Montreal, for the following purposes : To deal in clothing and wearing apparel of all kinds, umler the name of \"Country Club Casuals Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 5,000 common shares of a par value of $1 each ami 45.000 preferred shares of a par value t)f $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.\u2022 Given at the office of the Provincial Secretarv, this 5th «lay of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.0969-o 1994-64 Dagenais et Desjardins ltée Notice is hebery given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 11th «lay of May.1964.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Marcel Dagenais, merchant.11126 (îouin Blvd., East, Richmond Desjardins, annuitant.11596 (îouin Blvd.Fast, both of Quarticr-Rivière-dcs-Prai-ries, Montreal.an«l Paul-Emile Desjardins, merchant.14 St-Jean-Raptiste, Pointe-aux-Trem-bles, for the following purposes: To carry on a business ami industry dealing in lumber, under the name of \"Dagenais et Desjardins ltée\".with a total capital stock of $40,000, divided into 4.000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 10746 (îouin Blvd., East.Quartier-des-Prairies, Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 11th «lay of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969 2036-64 k3292 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 1964, .%'* année.No -'¦'> Damir Enterprises Inc.Avis m! donné qu'en vertu de la première partie de la Loi dee compagnie* «le Quebec, il a été accordé, par 1«- lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, 'les lettres patentes, en date \u2022 In 13e jour «le mai 1064, Constituant en corporation: Molvyn Hodes, Stuart Millowit/., Bênnie Berger, tous trois notaires, et (îaylaml Rediker, secrétaire, tous quatre de 1255, rue University, Montréal, pour les objets suivants: Kxerer le commerce d'une compagnie d'immeubles et «le construction, sous le nom «le « Damir Enterprises Inc.».avec un capital total de 640*000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 65 chacune, 38,000 actions privilégiées catégorie « A » d'une valeur au pair de SI chacune et 1.001) actions privilégiées catégorie « B » d'une valeur au pair de 61 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à chambre 509.1255, rue University, Montréal, «listrict judtciajre de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, «v LSejourde mai 1964.Le Sous-tecrvtaire de la prorince, Raymond Doivillk.6969 2157-64 Damir Enterprises Inc.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing «late the IStll day of May, 1964, have been leaned by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Melvyn Hbdai, Stuart Millowitx.Bcnnic Merger, all three notaries, and Gayland Rediker, secretary, all four of 1255 1'nivcrsity Street, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a resl estate and const rUCI ion company, tinder the name of \"Damir Enterprises Inc.', with a total capital stock of 840,000* divided into 200 common shares of a par value of 85 each, 38,000 class \"A\" preferred shares of a par value of SI each ami 1,000 class \"B\" preferred shares of a par value of Si each.The head office of the company will he at Suite 500.1255 1'niversity Street, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this L3th day of May, 1904.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.09i)0-o 2157-64 Danny Investment Inc.Avis est donné «pi'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, eu date du 30e jour «l'avril 1964, constituant en corporation: Arthur Peter Greenberg, comptable agréé, Ruth Bernstein, ménagère, épouse séparée «le biens «ludit Arthur Peter (ireenberg, et «lûinent autorisée par «\u2022«\u2022 dernier aux fins «les présentes, tous deux «le 5110, avenue Bessborough, Montréal, et Hyman Laddie Schuaiberg, avocat, 7460, chemin Kingsley, appartement 003.Côte-St-Luc.pour les objets suivants: Faire le Commerce d'articles vestimentaires «le toutes sortes, sous le nom «le f the Province of Quebec, incorporating: John McDougall, advocate, 491 Victoria Square, Nicole Crevier, 1550 Maisonneuve Street, and Lucy Brennan, 3820 St.Kevin Avenue, the latter two secretaries, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of photographers, under the name of \"Dek (Québec) ltée\", with a total capital stock of $20.000, divided into 100 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 1904, Vol.90, So.S 3293 Donné «m bureau «lu secrétaire de lu province, ce 27e jour d'avril 1964.Le Sous-eeeritaire de la province, Raymond Douvillb.Qm 1320-64 l'uni DeSSUreaU II const ruction inc.Avis esl donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du I2f the Province of Quebec, incorporating: Donat Lalibcrté, manufacturer, 11956 Albert-Dmpiesne.Montreal-North, Roland Lalibcrté, manufacturer, 3497, 43r«l St., St-Michel, ami Fugène Brouillet, advocate, 6502 Christophe-Colomb, Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in merchandise ami leather articles, in imitation leather, and in all other substances, under the name of \"Distinctive Leather Goods Limited\", with a total capital stock of 975,000, divided into 750 common shares «>f $100 each.The head office of the company will be at 3400 Métropolitain Blvd., East, room 203, Montreal, judicial district «>f Montreal.(îi.ven at the office of the Provincial Secretary, this 12th «lay of May.1904.R aymon i) Doll villk, Assistant Secretary of the Produce.6969 1820-64 Camille Dionne inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 29th day of April, 1964, have been issued by the Lieu tenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Camille Dionne, industrialist, Suzanne Lefebvre, wife contractually separate as to property of the said Camille Dionne, both of 9657, Merritt St., Montreal, and Lucien Lefrançois, accountant, 1920 Prieur St., East, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a oenstruction company, under the name of \"Camille Dionne inc.\", 3204 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 20 juin 1964, 90' année.No 25 avec nu capital total «le 140,000, dlviié en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 «\u2022hacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district jmlieiaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 20e jour «l'avril 1001.Le Sous-secrétaire de la province, Kaymomi Douville.6909-o 1862-64 with a total capital stock of $10.000.divided Into 2,000 common shares of a par value of $10 each ami into 2.(MX) preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the c«»mpan,v will he at Montreal, judicial «listrict of Montreal.(\u2022iven at the office of the Provincial Secretarv.this 29th day «>f April.1901.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.6969 1862-64 Do Harry Fabric Corporation Avis est «humé qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Quebec, il a été acj'onlé.par le lieu tenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date «lu 1er jour de mai 1904.coutituant en corporation: Louis Peigenbaum, avocat, .loan Peigen-bauni.secretaire, célibataire, tous deux «le 281, rue 'l'ait.Saint-Laurent, et Dimitri«»s A.Hadjis, avocat, 3456, rue Shuter, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de rembourrage et fournitures d'ameublement, tissus, étoffes et accessoires i des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 28e jour d'avril 1964, constituant en corporation: Richard La Charité, avocat, Claudette body, ménagère, épouse séparée de biens dudit ilichard La Charité, tous, deux de 12, 9e Avenue, ^te-Thérèse-Ouest, et Marguerite Houle, secrétaire, veuve d'AIdéric Trudelle, 176, Les Saules, St-Kustache, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Fere construction inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 408, rue Constantin, St-Eustache, district judiciaire de Terrebonne.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 28e jour d'avril 1964.Ix Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.0969-o 1517-64 Ferclerc inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of May, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Henri Choinièrc.advocate, Claude Lau/on, advocate, and Pierre Larocque, office clerk, all three of 54 St.James St.St.John's, for the following purposes : To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Ferclere inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 250 common shares of a par value of $100 each and into 150 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Iberville, judicial district of Iberville.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 12th day of May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969 2132-64 Fere construction inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of April, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Richard La Charité, advocate, Claudette Roily, housewife, wife separate as to property of the said Richard La Charité, both 12, 9th Ave., Ste-Thérèse-VVest, and Marguerite Houle, secretary, widow of Aldéric Trudelle, 176 Les Saules, St-Eustache, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Fere construction inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 408 Constantin St., St-Eustache, judicial district of Terrebonne.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of April, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969 1717-64 Jacques Ferland Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la Jacques Fcrland Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of May, 1964, have 3296 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 19(14, 90' année.No 2ô province dfi Québec, des lettres patentes, en date du 12e jour de mai 1964, const ituant on corporation: Jacques Ferland, entrai neuf, 1771), rue Notre-Dame, OUMt, Montréal, .laines McLean, fils, représentant «le ventes, 905, avenue Walnut, St-Lambert, et (Jayc M«m>rc, surveillant, 184, avenue Clinton, St-Lambert, pour les objets suivants: Faire le commerce de chevaux et entretenir et diriger toutes sortes d'écoles d'équitation, ranches et élahles, sous le nom de « Jacques Ferland Inc.», avec- un capital total de 610,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «le $10 chacune.In* siège social «le la compagnie sra à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire «le la province, ce 12e jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la prorince, Kaymon i) Douville.6969 1991-64 been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, incorporating: Jacques Ferland, trainer, 1779 Notre-Dame Street West, Montreal, James McLean Jr., sales representative, 305 Walnut Avenue, Bt-Lambert, and Gaye Moore, supervisor, 1S4 Clinton Avenue, St-Lambert, for the following purposes: To deal in horses and to maintain ami operate equitation schools, ranches and stables of all kinds, under the name of \"Jacques Ferland Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares «>f $10 each.The head oflice of the company will be at Montreal, judicial «listrict «>f Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of May, 1904.Raymond Douville, Assistant Secretary iif the Province.6969-0 1991-64 Fleur de Lys Carj»et Co.Ltd.Fleur de Lys Carpet Co.Ltd.La Cie de tapis Fleur de Lys ltée La Cie de taj>is Fleur de Lys ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en «late du 12e jour de mai 1904, constituant en corporation: Harohl W.Ashenmil, Julian K oiler, et Stanley il.Shuster, avocats, «le 901, rue Blcury.Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce «le couvre-planchers et d'accessoires de toutes sortes, sous le nom de f articles in leather or «>f fabric or material, umler the name of \"La Ganterie B.C.L.ltée B.C.L.(dove Ltd.\", with a total capital stock of 825,000, divided into 2.500 common shares of $10 each.The head office of the company will be at St-Pacdme, judicial «listrict of Kamouraska.Given at the office «>f the Provincial Secretarv.this 5th .lay of May, 1004.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.6060 1984-64 Lucien Gauvin inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accord-, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 30e jour d'avril 1904, constituant en corporation: Lucien Gauvin, négociant.Blanche H Ion in.ménagère, épouse cantractuellement séparée de biens dudit Lucien Gauvin, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de 1290, rue Lcmoinc, Québec, et Jacques Tasche-reau, notaire, 505, rue St-Joseph, est, Québec, pour les objets suivants: Commerce «le vêtements, sous le nom «le i «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du 14e jour «le mai 19(54, constituant en c«>rp-ration: Roger Levesque, constructeur, Ghislaine Mouchard, ménagère, épouse séparée de biens dudit Roger Levesque, tous deux «le 529, 9e Avenue, Laval-des-Itapides, et Albert Rivard.constructeur.2300, rue St-Zoti«pie, est.Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de construction et d'immeubles, sous le nom «le « Les Habitations Val d'Or inc.», avec un capital total «le $40.000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 529, 9e \\ venue, Laval-des-Rapides, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 14e jour «le mai 1904.Le Sous-secrftaire de la prorince, Raymond Doc yillk.6969-0 1882-64 To «leal in motor vehicles, their parts and accessories and to do business as garage keepers, under the name of \"(ilenwood Services Limited \u2014 Services (ilenwood limitée\", with a total capital stock of $40,000.divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office «)f the company will be at South-Hull, judicial district of Hull.Given at the office of the Pr«>vineial Secretary, this 21st day of April, 1904.Raymond DOUVILLB, Assistant Secreturu of the Province.6969m 1010-04 Les Habitations Val d'Or inc.Notice is hereby given that un 1er Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 14th day of May.1904, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province «>f Quebec, incorporating: Roger Leves-(|ue, builder.Ghislaine Bouchard, housekeeper, wife separate as to property «)f the said Roger Levesque, both of 529.9th Ave.Laval-dcs-Rapi-«les.and Albert Rivard, builder.2300 St-Zotique St., Fast, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a buil ling and real estate company, under the name of \"Les Habitations Val d'Or inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 529.9th Ave., Laval- hs-Rapides, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of May, 1961.Raymond Doivii.i.k, Assistant Secretary of the Province.6966 1882-64 Haeaino Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en «late du 4e jour «le mai 1964, constituant en corporation: Roland A.Diamond, notaire, 3055, rue Lacombe.Christine Diamond, secrétaire, célibataire, 3760 St-Kevin, app.2, et Mozes Koster, vendeur, 7030, côte St-Luc.tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «le placements, sous le nom de « Hacamo Ltd.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $10 chacune.200 actions privilégiées classe « A » de $10 chacune et en 3,600 actioas privilégiées classe « B » de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 4e jour de mai 1964.Le Sous-secret aire de la province, Raymond Doit villi-:.6969-0 1474S-62 Iberville Hardware (Que) Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies tie Quél>ec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 13e jour de mai 1964, constituant en corporation: Theodore Lecker, 5815, Trans Island, Marvin Looker, 5737.Mlossom, Harold Lecker.Hacamo Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 4th «lay «>f May, 1964.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Roland A.Diamond, notary, 3055 Lacombe.Christine Diamond, secretary, spinster, 3760 St-Kevin, apt.2, and Mozes Koster, salesman.7030 Côte St-Luc.all three of Montreal, for the following purposes: To operate as an investment company, under the name of \"Hacamo Ltd.\", with a total capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of $10 each, 200 preferred class \"A\" shares of $10 each and into 3,600 preferred shares «>f class \"R\" of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the officeiTf the Provincial Secretary, this 4th «lay of May.1964.Raymond Doi'villk, Assistant Secretary of the Province.6069 14748-62 Iberville Hardware (Que) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Québec Companies Act.letters patent, bearing «late the 13th «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Theodore Lecker, 5815 Trans Island, Marvin Lecker, 5737 Blossom, Harold Lecker, 5733 Lockwood.and GAZETTE OFFICIELLE DE QUE H EC.20 juin 1904, année.So i'ô 33(H) 5733.Lock wood, et David (irccnblatt.1745, Avenue Cedar, tous quatre administrateurs, «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer w commerce de quincaillerie, sous le nom f \"Ilx-rvillc Hardware (Que) Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into loo common shares oi a par value f 1100 each and 300 preferred shares of a par value of 810(1 each.The head office of the company will !»«\u2022 at Montreal, judicial district l the company will be al Mount Royal, judicial district of Montreal.(Jivcn at the office of the Provincial Secretarv.this 4th day «>f May.1004.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.6969-0 2012-01 Industries Bouchard inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 12th «lay of May.1904.have been issue»! by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Charles-Eugène Bouchard, industrialist, Mariette Dan-cause, housekeeper, wife contractually séparât»' as to property f the said Charles-Eugène Bou-chard, both of Ste-Anne-de-la-Focatière, ami Thérèse Bouchard, housekeeper, wife contractually separate as t«> property of Yves Robitaille.2805 Notre-Dame.St-Ilyacintho.for the following purposes: To carry on a business dealing in motor vehicles, their accessories and parts, umler the name of \"Industries Bouchard inc.\".with a total capita) sUx-k of 840,000, divided into 40.000 common shares of 81 each.The head office of the company will be at Stc-Anne-«le-la-Pocatière, judicial «listrict of Kamouraska.(iiven at the office of the Provincial Secretarv.this 12th day of May.1904.Raymond Dot ville, Assistant Secretary of the Province.6969 2125-64 Instant Sales Corp.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act.letters patent, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20.J.%-4, Vol.96, No.25 3.501 été accordé, par It- lieutenant-gouverneur de la province de Québec, dee l»-ttr«-s patentee, en dale \u2022 lu 1 le jour de mai 1964, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat et conseil en Loi de la Reine, 3733, Le Roiilevaro!, West mount, Theodore II.Shapiro, avocat, 5175, chemin f the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 11th «lay of May, 1964, hav«-e been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, incorporating: Louis Orenstein, advocate and Queen's Counsel.5664 MacDonahl.Hampstcad.Jason Ruby, advocate, 2860 Ekers Avenue, Montreal, and John Michelin, advocate, 5200 Prince of Wales, Montreal, for the foll«>wing purposes: To carry on the business of a steam and general laundry, umler the name of \"Koerner Enterprises Inc.\", with a total capital stock «>f $40.000.divided into 2.000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of 6100 each.The head office «>f the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 11th .lay of May.1964.Raymond DotTVIU i¦'.Assistant Secretary of the Province.0969-«> 2085-64 Lac Bowker Estates Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été a(?cor«lé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en «late du 5e jour de mai 1964, constituant en corpora-tion: Charles Brownstcin, avocat.6612, chemin Nice.Anne Belfer, secrétaire, fille majeure.6631, chemin Baily.tous deux «le Cte-Saint-Luc, et Mary (îoldwater, secrétaire, épouse séparée «le Mens de Sydney L.(îoldwater, 36, rue Avondale, l'ollard-des-Ormeaux, pour les objets suivants : Exercer le commerce «l'une compagnie de placements, d'immeubles et de construction, sous le nom «le « Lac Rowker Estates Inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 500 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le $10 chacune et 500 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Moutn'-al.district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 5e jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la prorince.Raymond Doivillk.\u2022'\u2022969 19K8-64 Lac Bowker Estates Ine.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Charles Brownstein, advocate, 6612 Nice Road, Anne Belfer, secretary, fille majeure, 6631 Baily Road, both of Côte-St-Luc, ami Mary (îoldwater, secretary, wife separate as to property of Sydney L.(îoldwater, 36 Avondale Street, Dollard-des-Ormeaux, for the following purposes: To carry on the business of an investment, real estate and construction company, under the name of \"Lac Bowker Estates Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 500 com mon shares of the par value of $10 each and 500 preferred shares f the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.(iiven at the office «>f the Provincial Secretarv, this 5th day of May, 1964.Raymond Doi: vii.i.k.Assistant Secretary of the Province.6969-o I9SK-64 Lionel E.Lalonge inc.Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en «late du lie jour de mai 1964, constituant en corporation: Lionel E.La longe, courtier en assurance.Lise Landreville, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Lionel E.Lalonge, et Lionel L.Lalonge inc.Notice is hereby given that under Part I «>f the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 11th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Lionel E.Lalonge, insurance broker.Lise Landreville, housekeeper, wife contractually separate as to property of the said Lionel E.Lalonge, and «luly 3304 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.M juin 1964, 96* année.A'o 86 dûment autorisée par lui aux fini «les présentes, tous deux f \"Lionel E.Lalonge inc.'', with a total capital stock «>f 840,000, divided into 2,000 common shares of $10 each end into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 132 Lorange St., Repcntigny, judicial district of Joliette.Given at the office of the Provincial Secretary, this llth day of May.1964.Raymond Douvillb, Assistant Secretary of the Province.6969 2027-64 G.Lumontagne.inc.Avis est «humé «pieu vertu «le la première partie «h- la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par l«- lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 12e jour de mai 1964, constituant en Corporation: Gaétan Lsmontagne, mécanicien, Suzanne Beauchamp, commis, épouse séparée de biens de Gaston Niquet, et Gisèle Beauchamp, commis.tous trois de Dolbeatt, pour Ie8 objets suivants: L'installation, la réparation «'t l'entretien de tous équipements af Quebec, incorporating : Gaétan La montagne, mechanic, Suzanne Beauchamp, clerk, wife separate as t«> property of Gaston Niquet, and Gisèle Beauchamp, clerk, all three of Dol- beau.for the following purposes: To carry «m a business in the installation, repairs and maintenance of all equipment operated by gasoline «»r oil, umler the name of \"(i.Lamon tagne, inc.\" with a t«»tai capital stock «»f 125,000, divided into 25.000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Mistassini.judicial district of Roberval.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 12th day of May.1964.Raymond Dorvn.i.i:.Assistant Secretary of the Province.09(59 1824-64 Ignace Langlais limitée Notice is hereby given that umler l'art I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 23rd «lay of March, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Ignace Lan glais, tradesman, Richard Langlais, forestry engineer, both of St-Pascal, and Ludger Langlais, accountant, Rivière-du-Loup, for the following purposes: To carry on business dealing in the industry ami business «>f lumber, under the name of \"Ignace Langlais limitée\", with a total capital stock of $40.000.divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at St-Pascal.judicial district of Kamouraska.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd «lay «>f March.19(54.Raymond Dorvii.i.k.Assistant Secretary of the Province.09(59 1813-04 - 1212/133 Larin Engraving (1964) Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the QttebêC Companies Act.letters patent, bearing «laie the llth «lay of May.1964.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Joseph Shapiro, advocate ami Queen's Councel.3733 The Roulcvard, Westmount, Jonathan J.Robinson.advocate, 64 Belvedere Road, Westmount.Théo- QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, .lune 20.1964, Vol.9f the company will !»«\u2022 at Montreal, judicial district of Montncal.(îiven at the ollic«' of tin- Provincial Secretarv.this 1st «lay of May, 1904.Raymond Douvillb, Assistant Secretnri/ of the I'rorince.6960-0 19f)S-oi Les Meubles Carrier, inc.Carrier Furniture, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par !«¦ lieutcnant-g«>uverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en «late «lu 1er jour d'avril 1904.constituant en corporation: KosarioCarrier, industriel.Emilien Roy, professeur, et Hay moud M adore, comptable agréé, tous trois de Mont-Joli, pour les objets suivants: Faire le commerce «le meubles et nouveautés «le Uni tel sortes, SOUS le nom de « Les Meuhles Carrier, inc.Carrier Furniture.Inc.», avec un capital total de 850,000, divisé en 200 actions onlinaires «le $100 chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Mont-Joli, «listrict judiciaire «le Kimouski.Donné au bureau «lu secrétaire de la province.08 1er jour d'avril 1904.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillb.6969-0 835-64 Ix;s Meubles Carrier, inc.Carrier Furniture, Inc.Notice is hereby given that umler l'art I «>f the Quebec Companies Act, letters patent, hearing «late the 1st «lay «>f April.1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Rosario Carrier, industrialist, Emilien Roy, professor.ami Raymond M adore, chartered accountant, all three «»f Mont-loli.for the following purposes To carry on a business dealing in furniture ami novelties of all kinds, under the name of \"Lei Meubles ( 'arrier.inc.- Carrier Furnitur«\\ Inc.\".with a total capital stock of 850,000 divided into 200 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Mont-loli, judicial district of Rimouski.(îiven at the «>thYe «>f the Provincial Secretary, this 1st «lay «>f April.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969 835-64 Miracle Mile Industrial Park Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du Se jour de mai 1904, constituant en corporation: Irving L.Adessky, 5789, Melling, Daniel Kingstone, 49S5, avenue loua, et Bra h m L.Campbell, Ô500, Snowilon, tous trois avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie «le placements, «l'immcubles et «le construction, sous le nom «le « Miracle Mile Industrial Park Corp.», avec un capital t«>tal «le $40,000.divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce Se jour de mai 1904.1a\" Sous- ecrétaire de la produce, Raymond Douvillk.6969 2074-(>4 Les Monarques de Loretteville inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 4e jour de mai 1964, constituant en corporation sans capital-actions: Marcel Linteau, fonctionnaire fédéral, Bruno Frenette, employé de la Cie Québec Power, Jean Bourhoin, publi-ciste, Serge Gignac, assistant comptable, Gaston Miracle .Mile Industrial Park Corp.Notice is hereby given that umler Part I «>f the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 8th «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Irving L.Adessky, 57S9 Melling, Daniel Kingstone, 49SÔ Iona Avenue, ami Brahm L.Campbell, 5500 Snowdon, all three advocates, of Montreal, for the following purposes: 'To carry on the business of an investment, real estate and construction company, under the name of \"Miracle Mile Industrial Park Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common snares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office «>f the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.(liven at the office of the Provincial Secretarv.this 8th day of May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the I'rorince.0969-o 2074-64 Les Monarques de Loretteville inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Marcel Linteau, federal government employee, Bruno Frenette, Quebec Power Co.employee, Jean Bourboin, publicist, Serge Gignac, assistant accountant. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 1964, Vol.96, So.2ô $309 Daiglo, contrôleur, tous cinq do Loretteville, et .l«-an-Paul Renaud, camionneur, Chateaii-d'Eau, pour les objets suivants: Contribuer aux loisirs de ses membres tout en leur donnant une formation culturelle et musicale, l'esprit de discipline, des notions «le chorégraphie, sous le nom de « Les Monanpies de Loretteville inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est «le 625,000.Le siège social «le la corporation scia à Loretteville, district judiciaire «le Québec.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce le jour «le mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doivillk.6969-0 1830-64 Montreal Associated Cleaners Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du v jour de mai 1904.constituant en corporation: Gilles Coulotnbe, avocat.H)?.\"), rue Ontario.Sherbrooke, Françoise PoUqUet, secrétaire, célibataire.1011.rue McManamy.Sherbrooke, et Florence Zaor, secrétaire, célibataire.1484, rue Belvédère sud, Sherbrooke, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le nettoyeurs, sous le nom «le « Montreal Associated Cleaners Inc.», avec un capital total «le 640,000, divisé en 100 actions ordinaires «le 810 chacune et 780 actions privilégiées «le $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1333, rue Sainte-Catherine est, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 8e jour de mai 1904.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Doi'villk.6966 208844 Murray's M & R Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec des lettres patentes, en «late du 13e jour de mai 1904.constituant en corporation: Samuel H.Shriar.2455.Vala«le.St-Laurent.Murray II.Spiegel.63, Ranstead.Montréal ouest.Harvey M.Cooperstone.144S, Beverley Crescent, Chomedey, tous trois avocats, et Sarah Shatzky.secrétaire, célibataire.5590, Jeanne Mance, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce «le blouses, robes et tous autres vêtements pour «lames, sous le nom «le I Murray's M & R Enterprises Inc.», avec un capital total «le 820,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de SI chacune et 16,000 actions privilégiées «le $1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 13e jour «le mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.0969 2155-64 Nivose ltée Nivôse Ltd.Gaston Daigle, comptroller, all five of Loretteville, and Jean-Paul Renaud, trucker, Ch&teau-d'Eau, for the following purposes: To contribute to the recreational facilities of its members by giving them a cultural and musical formation, the spirit «>f discipline, notions of choreography, umler the name of \"L«*s Monar-qties «le Loretteville inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire ami hold is to be limited, is 825,000.The bead office of the corporation will be at I/oretteville, judicial f the Provincial Secretary, this 4th day of May, 190 1.Raymond Doc ville, .[suintant Secretary of the Province.6960 1830-64 Montreal Associated Cleaners Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 8th day f May.1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gilles Cou- lombe, lawyer.1075 Ontario Street, Sherbrooke.Françoise Pouquet, secretary, spinster.1011 McManamy Street.Sherbrooke, and Florence Zaor.secretary, spinster.1484 Belvedere Str«-et South.Sherbrooke, for the following purposes: To carry on the business of cleaners, under the name of \"Montreal Associated Cleaners Inc.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 100 common shares «>f $10 each and 780 preferred shares «>f $50 each.The bead office of the company will be at 1333 Ste-Catherine Street Fast.Montreal, judicial «listrict of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 8th day of May.1964.Raymond Dor ville.Assistant Secretary of the Prorince.6909-o 2083-64 Murray's M & R Enterprises Ine.Notice is hereby given that umler Part I of the Qucliec Companies Act.letters patent, bearing «late the 13th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Samuel H.Shriar.2455 Valade.St-Laurent.Murray B.Spiegel, 03 Banstead.Montreal West, Harvey M.Cooperstone, 144S Beverly Crescent.Chomedey, all three advocates, and Sarah Shat/.ky, secretary, spinster, 5590 Jcannc-Mancc, Montreal, for the following purposes: To deal in blouses, dresses and all other women's apparel, umler the name of \"Murray's M & It Enterprises Inc.\".with a total capital stock of $20,000.divided into 4.000 common shares of $1 each and 10.000 preferred shares «>f $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of May.1904.Raymond Doivillk.Assistant Secretary of the Prorince.0969-o 2155-64 Nivose ltée Nivose Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent* 33 îo GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC.20 juin 1964, 06* année.So 25 été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «I»' Québec, «les lettres patentes, en «lato du 8e jour «l'avril 1064, constituant en corpora* tien: Pierre Massé.Cilles Y.Renaud et Jean Duchesne, tous trois avocats, t donné qu'en vertu «le la première partie de la I.oi des compagnies de Quebec, il a été accordé, par le lioutenant-gcjuverncur «le la province «le Quebec, «les lettres patentes, en «late «lu 16e jour «le mars 1904.constituant en corporation: Jean T.Vieil, avocat.3445.cote des Neiges, Montréal.Micheline I.alande, secrétaire, épouse séjiarée f March.1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean T.Vicn.advocate, 3445 Cote, «les Neiges, Montreal, Micheline Lalande, secretary, wife separate as t property of Guy Leduc, 8102 Viau Blvd., St- Leonard, and Christine Diamond, secretary 224 St-Joseph Blvd., Fast.Montreal, for the following purposes: To carry on a business as pastry-makers and bakers in all their specialties, under the name of \"Patisserie Legault inc.- Legault Pastrj Inc.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 500 c«)inmon shares «if a par value of $1 each ami into 3,950 preferred shares of a par value of $10 each.The head office «>f the company will be at 2288 Rélanger St., Fast, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary this 16th «lay of March.1904.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.0909 1205-64 Pavage Ste-Foy inc.Notice is hereby given that umler Part I «»f the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 0th «lay of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating : ( îérard Lemay.contractor, Aline Deniers, housekeeper, wife contractually separate as to property of the said Gérard Lemay, both of 978 Pouliot Ave., and Eugène Deniers, chauffeur, 851 Church Read, all three of Ste-Foy, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Pavage Ste-Foy inc.\", with a total-capital stock of $50,000, divided into 500 common shares of $100 each.The head ollicc of the company will be at 978 Pouliot Ave., Ste-Foy, judicial district of Quebec.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 6th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969 2046-64 QYEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 196^, Vol.96, No.25 3313 Perrault Lumber Ine.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de lu Iy.all three advocates, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Les Placements Moberge inc.\".with a total capital stock of $20,000, divided into 300 common shares of a par value of $10 each and into 1,700 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 133 Trudel Street, Quebec, judicial «listrict of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th «lay of May, 1904.v Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.6969 2130-04 Poulin & Rodrigue inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Quél>ec, des lettres patentes, en date du 5e jour de mai 1964, constituant en corporation: Joseph Giroux, infirmier, Beauceville, Florent Quirion, agent-vendeur, Beauceville-Est, et Claude I/ongchamp, électronicien, Beauceville, pour les objets suivants: Fabrication et commerce de produits métalliques, sous le nom de « Poulin & Rodrigue inc.», avec un capital total «le $35.000, divisé en 350 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Reauce- ' ville-Est, district judiciaire de Reauce.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 5e jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.6960-o 2021-64 Poulin & Rodrigue inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Joseph Giroux, male nurse, Beauceville, Florent Quirion, sales agent, Beauceville-East, and Claude Long-champ, électronicien, Beauceville, for the following purposes: To manufacture ami carry on a business dealing in metallic products, umler the name of \"Poulin & Rodrigue inc.\", with a total capital stock of $35,000, divided into 350 common shares of $100 each.The head office of the company will l>e at Beauceville-East, judicial district of Beauce.Given at the office of the Provincial Secretary, this 5th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969 2021-64 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 1964, >'o/.%', So.2ô 3315 Prefin inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de lu Loi des compagnies de Québec, il u été uccordé, pur le lieutenant-gouverneur «le lu pr«)vince «le Québec, des lettres putentes, en dute du 13e jour de mai 1901, constituunt en corporation: Jean Miiic Baronet, industriel, 1140, Kousseau, Sillery, Roger Lefrançois, contrôleur, il 17, «les Frênes, Québec, et Lan ré an ne Breton, secrétaire, 1270, William, Sillery, pour les objets -uivants: Faire affaires comme compagnie de financement, sous le nom de « Prefin inc.», avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair ou nominale et en 1,000 a«-tions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 331, rue Turcotte, Québec-Ouest, «listrict judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire «le la province.< e 13e jour «le mai 1904.Le Soun-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.$969-0 2131-04 Prefin inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 13th «lay of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean-Marc Baronet, industrialist, 1140 Rousseau, Sillery, Roger Lefrancoia, comptroller, 307 des Frênes, Quebec, ami Lauréanne Breton, secretary, 1270, William, Sillery, for the following purposes: To carry on business as a financial company, under the name of \"Prefin inc.\", with a capital stock divided into 1.000 common shares without nominal or par value ami into 1,000 preferred shares f May.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.0909 2131-04 I^es Produite de verre scellé ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été acconlé.par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du lie jour «le mai 1904, constituant en corporation' Philippe Leduc, commerçant.075, 9e Hue, St-Antoine-des-Laurentides.Wilfrid lapierre, comptable.801, 10e Avenue.St-Antoim»-des-Laurentides.et Jean-Claude Raymond, vendeur, 8, avenue Morand, St-Jénmie.pour les objets suivants: Industrie et commerce «lu verre et tous autres produit! s'y rapportant, sous le nom «le « Les Produits «le verre scellé ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 750.hou!, des Laurentides, St-Antoine-des-I.aurenti«les, «listrict judiciaire «le Terrebonne.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 1 le jour «le mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.6989-0 1843-64 Les Publications Métro-Express limitée The Metro-Express Publishing Company Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a «'\u2022té accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 21e jour «l'avril 1904, constituant en corporation: .lean ni ne Gilbert, secrétaire, célibataire, 1040, avenue Bail.Montr«:al, Maurice Coutu, distributeur de périodiques, 16001, Ste-Croix.Pierrefontls, Llewellyn, S.Reycraft, avocat et conseil en loi «le la Reine, 2960, avenue Glencoc, Montréal, Trevor H.Bishop, avocat, 42, chemin Belvédère, Montréal.Bruno Desjanlins.avocat, 58, Jeaimotte, Bcloeil, Barry Sterndale Bennett, administrateur de compagnie, 3525.rue Shuter.Montréal, Rose Tworck, secrétaire, divorcée, 4056, Jeannc-Mance, Montréal, Y von Turcot, journaliste, 5334, rue Berri, Montréal, et Roland G.Chauvin, avocat, 11530, avenue Dépatie.Montréal, pour les objets suivants: Les Produits de verre scellé ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing «late the lltli «lay «)f May, 19*54, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, incorporating: Philippe Leduc, tradesman.675.9th St.St-Antoine-dcs-Laurentitles, Wilfrid Lapierre, accountant, 501, 10th Ave.St-Antoine-des-Laurentides.and Jean-Claude Raymond, salesman.9 Morand Ave., St-Jérôme, for the following purposes: To carry on business ami industry «lealing in glass ami in all products pertaining thereto, under the name of Les Produits de verre scellé ltée\".with a total capital stock of $40.000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 750 «les Laurentides blvd., St-Antoine-des-Laurentides, judicial district of Terrebonne.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 11th day «>f May.1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969 1343-64 Les Publications Métro-Express limitée The Metro-Express Publishing Company Limited Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 21st «lay of April, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, incorporating: .lean ni ne Gilbert, secretary, spinster, 1040 Ball Ave., Montreal, Maurice Coutu, distributor of magazines, 16001 Ste-Croix, Pierrcfonds, Llewellyn S.Reycraft, advocate ami Queen's Councel, 2960 Glencoe Ave., Montreal, Trevor II.Bishop, advocate, 42 Belvedere Road, Montreal, Bruno Desjardins, advocate, 58 Jeannotte, Beloeil, Barry Sterndale Bennett, company administrator, 3525 Shuter St., Montreal, Rose Tworek, secretary, «livorcee, 4656 Jeanne-Mance, Montreal, Y von Turcot, journalist, 5334 Berri St., Montreal, and Roland G.Chauvin, advocate, 11530 Dépatie Ave.Montreal, for the following purposes : GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 1964.96' année.No 25 3316 Exercer le commerce «le propriétirei de jour- nuux et pério«li«pies, éditeurs, imprimeurs, graveurs, relieurs, lithografhcs, libraires et autres Commerces semblables, SOUS le nom «le « Les Publications Métro-Express limitée - The Me- tro-Fxpress Publishing Company Limited )), avec un capital divise en 10,000 actions ordinaires sans valeur au pair et en 4.000 actions privilé iées de $25 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, Ce 21e jour d'avril 1964.Le Soux-xecrétaire de la province, Ravmonn Doivillk.6969-o 1809-64 K.Cm l.ogginf2 Compam Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a «Hé aet-ordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 8e jour «le mai 1904, constituant en corporation: Gilles Durand, comptable, Claire Lalonde, ménagère, épouse séparée «le biens dudit Gilles Durand, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous «leux «le 88Ô2, Esplanade, Montréal, et Monique Kéroack, secrétaire, célibataire, 2174, avenue des Cèdres, St-Hruno, pour les objets suivants- Exercer un commerce «le marchands de l>ois, sous le nom «le « R.C.Logging Company Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 585, rue Fleury, ouest.Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 8e jour «le mai 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.6969 2089-64 To carry on business as proprietors «>f newspapers ami periodicals, ai editors, printers, engravers, book-binders, lithographers, librarians and in other similar trades, under the name of \"Lea Publications Métro-Express limitée* The Mr.tro-Expresi Publishing Company Limited\", with a capital stock divided into H).(MH) common shares «>f no par value ami 4,000 preferred shares «>f $25 each.The head Office of the company will be nl Montreal, judicial «listri«-t of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of April.1964.Raymond Dot vii.i.k.Assistant Secretary of the Prorince.6969 1809-01 R.C.Ixigging Company Ltd.Notice is hereby given that umler Part I ol the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 8th «lay «>f May.1964.have been issued by the Lieutenant-Governor f Saguenay.Given at the office of the Provincial Secretarv.this 13th .lay of May.1964.Raymond Douvilli:.A.existant Secretary of the Province.0909 1457-04 Richelieu Purk Development Limited Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th «lay «»f May, 1964, have been issued by the Lieutenant \u2022Governor of the Province of Quebec, incorporating: Lasslo Sseme- nyei, advocate, 5012 King Kdwunl.Montreal, Renée Mignault, secretary.2185 Sauriol, Montreal, and Maire Marston.secretary.1292 Godin, Verdun, for the following purposes: To do business in the fields of real estate and construction, under the name of \"Richelieu Park Development Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4.000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of May.1964.Raymond Douviî.i.i.Assistant Secretary of the Province.6969-e 1831-64 Roger Rioux inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quel>ec Companies Act.letters patent, bearing date the 4th day of 1964.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Roger Rioux, mortician, Thérèse Santerre.housekeeper, wife contractually separate as to property of the said Roger Rioux, both of 70 Jean-Riou St.and Charles E.Pelletier, accountant, 12 Notre-Dame, all three of Trois-Pistoles.f«>r the following purposes : To carry on business as morticians, under the name of \"Roger Rioux inc.\".with a capital stock divided into 500 common shares without nominal or par value.¦ The head office of the company will be at Trois-Pistoles, judicial district of Kamouraska.Given at the office of the Provincial Secretarv.this 4th day of May.1964.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.6969 1981-64 Rocheleau construction inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent. 3318 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 19(4, W année.No 26 été accordé, pur le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 27e jour «l'avril 1964, constituant en corporations Jean Rocheleau, constructeur, Georgette Touchette, ménagère, épouse séparée «le biens dudit Jean Hoclieleau, et «lûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux «le 212.Monseigneur-Prévost.St-Fustaehe.et Constant Montanaro, comptable, 10895, rue Rancourt, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom «le « Rocheleau construction inc.», avec un capital total «le $100,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à St-\u2022 Eustache, district judiciaire «le Terrebonne.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 27e jour «l'avril 1904.Le Sous-secrétuire Je la province, Raymond Douvillk.0969-o 1853-04 Georges J.Roi/.in Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 8e jour «le mai 1904.constituant en corporation: Georges-Joseph Roizin, vendeur, Denise Ainbinder, ménagère, épouse séparée de biens dudit Georges-Joseph Roizin.et «lûment autorisée par ce dernier aux fins «les présentes, tous deux «le 8527.rue Mayrand, Montréal, et Julius Rosen-blum.avocat et conseil en loi «le la Reine, 2250, chemin Duncan, Mont Royal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le vêtements, sous le nom «le « Georges J.Roizin Enterprises Inc.».avec un capital total «le $25,000.divisé en 125 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 125 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 8e jour de mai 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.6909 2075-04 Romar (Fairview) Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du Se jour «le mai 1904, constituant en corporation: Isidore Greenhaum, 015.Westluke, Côte-St-Luc, Baruch Pollack, 0085, De Vimy, Montréal, Aaron Pollack.1827, avenue Nord, Montréal, tous trois avocats, et Morris Shuter, gérant de bureau, 874.Bertrand.St-Laurent, pour les objets suivants: Faire le commerce d'articles vestimentaires pour dames, sous le nom «le « Romar (Fairview) Inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3.500 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 8e jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.6969 2072-64 bearing «late the 27th «lay of April, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean Ro cheleau, constructor.Georgette Touchette, house keeper, wife separate as t«> property of the said Jean Rocheleau, and «luly authorized by him foi these presents, both of 212 Monseigneur-Prévost St-Eustache, and Constant Montanaro, accoun tant, 10395 Rancourt St.Montreal, for the fol lowing purposes: To carry on business as builders ami genera building contractors, umler the name of \"Roche leau construction inc.\", with a total capital stoc! of $100,000.divided into 5,000 common shares ol $10 each ami into 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be al St-Eustache, judicial «listrict of Terrebonne.(iiven at the office «>f the Provincial Secretan this 27th «lay of April.1904.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.0909 1853-01 Georges J.Roi/.in Enterprises Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 8th f these presents, both ol 8527 M ay rand Street, Montreal, and Julius Rosenbium, advocate ami Queen's Counsel 2250 Duncan Road, Mount Royal, for the following purposes: To deal in clothing, under the name of \"Georges J.Roizin Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $25.000, divided into 125 common shares of the par value «>f $100 each and 125 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretarv this 8th day of May.1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969-o 2075-0, Romar (Fairview) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent bearing «late the 8th «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of tin-Province of Quebec, incorporating: Isidore Greenhaum, 015 Westluke, Côte-St-Luc, Baruch Pollack, 0085 De Vimy, Montreal, Aaron Pollack 1827 North Avenue, Montreal, all three advocates, ami Morris Shuter, office manager, 87-1 Bertrand, St-Laurent, for the following purposes: To deal in women's apparel, under the name ol \"Romar (Fairview) Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 5,000 common shares of a par value of $1 each and 3,500 prefer red shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 8th day of May, 1964.Raymond Douville, \u2022 Assistant Secretary of the Province.6969-o 2072-64 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June SO, 1964.Vol- 00, No, 25 3319 Salle Do-Ré-Mi lue.Avis est donné qu'en vertu île la première partie «le la l.oi «les compagnies «le Québec, il a été accordât par le lieutenant-gouverneur «le la I ovince «le Québec, «les lettres patentes, en «late \u2022 lu 29e j«mr «l'avril 1964, constituant en corporation: Rémi .loyal, administrateur.Antoinette Pépin, ménagère, épouse séparée «le biens dudit Rémi .loyal.Daniel .loyal, évalua leur, et Jean Joyal, étudiant.t«»us «piatre de 223, Qm-rbes, tliitremont, pour l«\\s objets suivants: Exploiter «les salles «le «lanse et faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de «Salle I )o-R«'-Mi inc.», avec un capital total «le 850,000, ilivisé en 400 actions onlinaires «le $100 chacune «l en 100 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 7474, rue St-Hubert, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 29e jour «l'avril 1904.Le Sous-secrétaire de la prorince.Raymond Douvillk.6969m 357-04 Salle Do-Ré-Mi inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 29th r the following purposes: To operate «lan«-e halls ami to carry on business as restaurateurs, under the name of \"Salle Do-Ré-Mi inc.\", with a total capita! stock of $50,000, divided into 400 common shares of $100 each and 100 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 7474 St.Hubert Street.Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th «lay of April.1904.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Prorince.6909 357-04 Salon de haute couture Jacqueline inc.Avis est donné ««n'en vertu «le la première partie «le la Loi «ies compagnies «le Québec, il a été acconlé.par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 12e jour «le mai 1964, constituant en corporation: Claude Béland, 2870, Gleneee, Montréal, Jean Radeaux.197, DuHerin, Hampstead, et Louis A.'Poupin.352, Meloclie.St-Laurent, tous trois avocats, p«>ur les objets suivants: Exploiter un atelier «le haute couture, sous le nom «le « Salon «le haute couture Jacqueline inc.», avec un capital total de 830,000.divisé en 1.000 actions onlinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montreal, «listrict judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 12e jour de mai 1964.Le So us secrétaire de la province, Raymond Douvillk.6969-0 1997-64 Salon Elysée coiffure ltée Elysée Beauty Salon Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en date du 2e jour de mai 19(54, constituant en corporation: Lawrence Marks, cit., avocat, 656, avenue Grosvenor, Westmount, Mark Edmund Gordon, avocat, 36, Roxlxirough, Westmount, et Madeline Ferguson, secrétaire, fille majeure, et jouissant de ses droits, 1460, rue McGregor, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de coiffeurs, barbiers, manicuristes pédicures, masseurs du corps et du visage, bains de beauté, maquillage facial, sous le nom «le « Salon Elysée coiffure ltée \u2014 Elysée Beauty Salon Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de *10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Salon de haute couture Jacqueline inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 12th «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Claude Béland, 2870 Gleocoe, Montreal, Jean Badeaux, 197 Dufrerin, Hampstead.and Louis A.Toupin, 352 Meloclie, St-Laurent, all three advocates, for the following purposes: To operate an haute couture shop, under the name of \"Salon de haute couture Jacqueline inc.\", with a total capital stock of $30,000.divided into 1,000 common shares of $10 each ami 2,000 preferred shares «)f $10 each.The hem! office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 12th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969 1997-64 Salon Elysée coiffure ltée Elysée Beauty Salon Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 2nd «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Lawrence Marks, q.c, advocate, 656 Grasvenor Avenue, Westmount.Mark Edmund Gordon, advocate, 36 Roxborough.Westmount, and Madeline Ferguson, secretary, spinster of the full age of majority and in the full enjoyment of all her rights, 1460 McGregor Street, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of hairdressers, barbers, manicurists, pedicurists, body and facial massages, beauty baths, facial make-up, under the name of \"Salon Elysée coiffure ltée \u2014 Elysée Beauty Salon Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each ami 3,000 preferred shares of $10 eech.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 8320 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juiy 1964, 96' année.No $6 Donné au bureau du secrétaire de lu province, Ce 2e jour «le mai 1964.Le Sous-secrétuire de la prorince, Raymond Doivillk.mm 1977-64 Scalia Development l.id.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, eu date «lu 27c jour «l'avril 1964, constituant en corporation: Marcel Landry, avocat, Montée Prévert, Ib-loeil, Jacques Lemaître Auger, étudiant en droit, 2830, bout Rosemont, et Prançois Payette, avocat, 0029, boni.Gouin, ouest, ces deux «lerniers «le Montréal.p«»ur les objets suivants: Faire affaires connue constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, bous le nom «le « Scalia Development Lt«l.», avec un capital total «le 840,000, divisé eu 40 actions ordinaires de $100 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont-réal-Nord, «listrict judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province.Ce 27e jour «l'avril 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.6969-o 1848-64 (liven at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969-0 1977-01 Scalia Development Ltd.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 27th day of April, 1904, have been issued by the Lii'iiteiiaut-tJovernor of the Province of Quebec, incorporating: Marcel Landry, advocate, Montée Prévert, Reloeil.Jacques Lemaftre Auber, student-at-law, 2830 Rosemont Blvd., and François Payette, advocate, 9029 Gouin Blvd., West, the two latter of Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders ami general building contractors, under the name of Scalia Development Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 40 common shares «>f $100 each and 3.0(H) preferred shares of $10 each.The heatl office of the company will be at Montreal-North, judicial «listrict of Mon! real.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of April.1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969 1848-01 Scafortb Radiology Associates Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en date «lu lie jour «le mai 1964, constituant en corporation: David Henry Holland, avocat, 555, avenue Cur/.on, St-Lambert, Ernest William Mockridge, gérant, 324, avenue Mcrcille, St-Lambert, Clifford George Meek, comptable, 3101, avenue Maplewoo*!, Montréal, Theodore William Martinson, commis, 4217, avenue Western, Westmount, an«l Guy Ambrose Miller, gérant de perception, 1300, chemin De Carillon.St-Bruno, pour les objets suivants: Diriger et administrer un ou plusieurs bureaux médicaux et centres de ra«liologie.sous le nom de « Seaforth Radiology Associates Inc.», avec un capital total «le $40,000.divisé en 10,000 actions ordinaires, «l'une valeur au pair de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce lie jour «le mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.6909 2049-64 Scawdy Nursery & Landscaping Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Ix>i des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du 13e jour «le mai 1904, constituant en corporation: Pierre Chèvrefils, avocat, Ste-Martine, comté «le Châteauguay, Yves Ampleman, avocat, Beauharnois, et Denis Laberge, comptable, Ste-Martine.comté «le ChAteauguay, pour les objets suivants: Seaforth Radiology asociales Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the llth day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: David Henry Holland, advocate, 555 Cur/on Avenue, St-Lambert, Ernest William Mock ridge, manager.324 Mercille Avenue.St-Lambert, Clifford George Meek, accountant, 3101 Maplewood Avenue, Montreal, Theo«lore William Martinson, clerk, 4217 Western Avenue, Westmount, and Guy Ambrose Miller, collection manager, 1300 De Carillon Road.St-Bruno.for the following purposes : To operate ami manage one or more medical offices an«l radiology centers, under the name of ''Seaforth Radiology Associates Inc.\", with a total capital sttx-k of $40,000, divided into 10,000 common shares of the par value of $1 each and 30.000 preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this llth day of May.1964.Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.6969-o 2049-0! Seaway Nursery & Landscaping Co.Ltd' Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Pierre Chèvrefils, a«lvocate, Ste-Martine.county of ChAteauguay, Yves Ampleman.advocate.Beauharnois.and Denis Laberge, accountant, Ste-Martine, county of Châteauguay, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 190j, Vol.90, ,Vo.U Faire affaires comme fleuristes, pépiniéristes el CUlUvatouri «le graines, sous le nom «le « Seaway Nursery & Lamlscaping Co.Ltd.», avec un capital total «le 640,000, divise en 1,000 actions onlinaires «l'une valeur nominale «le $5 cliaeune «-t en 7,000 actions privilégiées «l'une valeur nominale «le $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à ( lhateeu- giiay-Centre.«listrict judiciaire «1f the company will be at Chftteauguay-Centre, judicial district «>f Beauhar-nois, (iiven at the ollieeiof the Provincial Secretary, this 13th day «>f May, 1964.Raymond Douvillk, A.isixtanl Secreturi/ of the I'rorince.6969 2147-64 La Seigneurie Pierre Roucher Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 8th «lay of May, 1904.have been issue*! by the Lieutenant-Governor f the Province of Quebec, t«> incorporate as a corporation without share capital: Rolaml Dumais, architect, 340 Wiseman, Montreal, Victor Duhamel, notary, 528 Notre-Dame Street, Boucher-ville, Aimé Racioot, builder, 4 de Grandpré, Boueherville, Dr.Stephen Langevin, physician, 1210 Marie-Victorin, Boueherville, Joachim Savaria, farmer, «le Lustucru Range.Boueherville, Mario Du Mesneil, advocate.420 Marie-Victorin Boulevard, Boueherville, J.-L.Montarvitle Boucher «le la Bruère.accountant, 23 Goupil Street.Sorel, Thérèse Bélisle, housewife, wife separate US*to property of Dr.Maurice Bélisle, and duly authorized by him for these presenls, 278 Marie-Victorin, Boueherville, Dr.Fernand Dagenais, physician, 11 «le Tilly, Boueherville.Charles Desmarteau, scenario-writer, 414 Marie-Victorin Boulevard, Boueherville.Léo Roy, professional engineer.1085 Marie-Victorin.Boueherville.Willie Lamothe.contractor, 99 Iles Percées, Boueherville, Maurice Corbeil, industralist, 491 Stuart Street.Outremont.Jean-Paul Auclair, editor.140 Marie-Victorin, Boueherville, Denis Racicot, merchant, 511 Ste-Marguerite Street, Boueherville, Yves Rinfret.publicist, 00 de Caumont Street, Boueherville, ami the Honourable Louis-F.Cantin, «listrict Judge, 344 Marie-Victorin Boulevard, for the following purposes: To group into an association the persons interested in the history of Boueherville, umler the name of \"La Seigneurie Pierre Boucher\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is §2,000,000.The head oflice of the corporation will be at Boueherville, judicial «listrict of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretarv, this 8th «lay of May.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.0909 2301-04 Skimont inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Rernard Des jar la is, advocate, 1600 Stephens, Verdun, Louis Vaillancourt, a«lvocate, 4519 Oxford, Montreal, and Roma Cousineau, advocate, 5652 Drake, Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Skimont 3322 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 1964.96' année.Xo 25 «le « Skimont ine.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées «le $30 chacune.Ia' siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 13e jour de mai 1001.Le Sous-secrétaire île lu province, Raymond Dot vii.i.k.6060-0 2154-04 Sogedis Ré»' Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 27e jour d'avril 1904.constituant en corporation: Raymond D'Auteuil, commerçant, 205, boul.Sacré-Coeur.Gérard Founder, industriel, 203.boul.Sacré-Coeur, et Alfred LeBcl, comptable.79.3e rue, tous trois de Rimouski.pour les objets suivants: Commerce de pièces de véhicules automobiles, objets de quincaillerie et effets connexes, sous le nom de « Sogedis ltée », avec un capital total de $100.000, divisé «mi 2.000 actions ordinaires de $20 chacune et en 3.000 actions privilégiées de $20 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 107.rue Ouellet, Rimouski.district judiciaire de Rimouski.Donné au bureau «lu secrétaire de lu province, ce 27e jour d'avril 1901.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillb.6969-0 1501-04 Sonora International Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été acconlé.par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 1er jour «le mai 1901.constituant en corporation: William I.Miller, avocat, 10, rue St-Jacques, ouest, Louis R.Grant, et Frank TIapa, ces deux derniers administrateurs, 1400 avenue des Pins, ouest, tous trois «!f Rimouski.f«»r the following purposes: To deal in parts for motor vehicles, objects of hardware and similar articles, umler the name of \"Sogedis ltée\".with a total capital stock of $100.000, divided into 2.000 common shares ol $20 each and 3,000 preferred shares of $20 each.The head office of the company will be at 107 Ouellet St.Rimouski.judicial «listrict of Rimouski.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th «lay of April, 1901.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.0909 1501-1.1 Sonora International Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 1st «lay of May.1904, ha\\< been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: William I Miller, advocate, 10 St.James Street West.Louis R.Grant ami Prank TIapa.the latter two executives, of 1400 Pine Avenue West, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an electrical and electronics company, under the name of \"Sonora International Ltd.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1.000 common shares of $10 each ami 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.0969-o 1956-01 Soudure G & G ltée Notice is hereby given that under Part'I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the llth day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Adrien} R.Paquette, Marcel Paquette.advocates, of 132 St.James St.West, suite 411.Montreal, and Rolande Yaillaneourt, secretary, fille majeure.8575 Hoehelaga, Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 1964.Vol.96, Ho, 96 3323 Faire le commerce «le toutes sortes d'appareils ou système! de «'huuffage et f the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 22nd «lay of May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.09G9-o 3974-63 Superior Manufacturing Co.Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 6th «lay of May.1964.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Albert Gagnon, manager.Pierrette (iagnon.housewife, wife separate as to property of the sai«l Albert Gagnon.and Anna Poirier, retired, widow of the late Wilfred (iagnon.all three of 8895, 1st Avenue.Montreal, for the following purposes: To deal in wealing apparel, umler the name of \"Superior Manufacturing Co.Ltd.\", with a total capital stock of $10.000, divided into 500 common shares of $10 each and 500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this Oth «lay of May, 1964.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.6969-o 1923-64 T.P.G.construction ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a té accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 4e jour de mai 1964, constituant en corporation: (iuy Boissonncault, Gilles Boissonneault t Bernard Casgrain, avocats, de 60, rue St-Jacqttes, ouest, suite 400, Montréal, pour les objets suivants: T.P.G.construction ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 4th «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: (iuy Boissonncault, Gilles Boissonneault, and Bernard Casgrain, advocates, 60 St-James St., West, suite 400, Montreal, for the following purposes: GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 19(11,, 96' année.No 2ô Faire alfaires comme compagnie «le constrtic-tion, sous le nom «le « T.I*.Ci.construction ltée ».avec un capital total «le $40.000.divisé «m 400 actions onlinaires de $100 chacune.Le liège s«m-ial «le la compagnie s«>ra 1594, boul.Lévesque, Duvernay, «listrict judiciaire de Mont-real Donné au bureau du secrétaire «le la province.«\u2022«\u2022 le jour «le mai 1004.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Doc vii.i.k.0009.1407-04 K.Tétreault & (ils liée Avis est donné qu'on vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 30e j«)iir d'avril 1904.constituant en «-orporu-tion: Filgar Tétreault, 1507, rue Montarville, St-Brun«>.Jacques Tétreault, 1507, rue Monter-ville, St-Bruno, tous «leux barbiers, André Tétreault, comptable agréé, 3871, rue Beaubien, est, app.11.Montréal.Paul Tétreault, comptable, 1507, rue Montarville, St-Hruno.et Pierre Tétreault.étudiant, 1507.rue Montarvill»', St-Hruno.p«)iir les objets suivants: Exercer «lans toutes ses spécialités le commerce d'entrepreneurs «le pompes funèbres, sous le nom «le « F.Tétreault & lils ltée », avec un capital total de $50,000, «livisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 1667, rue Montarville, St-Hrun«>.district jmlieiaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 30e jour «l'avril 1904.Le Sous-secrétaire de la prorincc, Raymond Douvillk.6969-0 1875-64 To carry on business as a construction com pany, under the naine of \"T.P.G.construction ltée\".with a total «apital stock «>f $40,00(1 «livide»! into 100 common shares of $100 each.The head office f the company will be at 1594 LévesqUe Blvd., Duvernay.judicial «lis trict of Montreal.(îiven at the office of the Provincial Secretary, this 4th «lay «>f May.1064.Raymond Dou villi.Ax.*islant Secretary of the Province.6008 1407-64 E.Tétreault & fils ltée Notice is hereby given that umler Part I «>i the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 30th day of April.1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of tin Province «>f Quebec, incorporating: Fdgar Tétreault, 1507 Montarville St., St-Hruno.Jacques Tétreault.1507 Montarville St., St-Hruno.both barbers, Amlré Tétreault, chartered accountant, 3871 Beaubien St.Fast, apt.11.Montreal, Paul Tétreault, accountant, 1507 Montarville St., St-Bruno, and Pierre Tétreault.student.1507 Montarville St.St-Hruno, for the following purposes: To carry on business, in all its specialties, a-undertakers, Under the name of \"F.Tétreault & fils ltée\", with a total «-apital stock of $50.000.divided into 100 common shares of $100 each ami 400 preferred shares of $100 each.a> The head office of the company will be at 1667 Montarville St.St-Hruno, judicial «listrict of Montreal.(iiven at the office «>f the Provincial Secretarv.this 30th «lay of April, 1904.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.6060 1876-64 I^e Théâtre de la Place Ville-Marie inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date «lu 6e jour «le niai 1904, constituant en corporation: P.-Wilbrod Gauthier, 1985, avenue Belle-vue, St-Bruno, Pierre I a-grand, 415, Place «l'Amiens, Duvernay, Pierre Cimon.12, rue «le Provence, Préville, L.-Yves Fortier.40, Arlington, Westmount, Raymond Crevier, 245, avenue Outremont, Outremont, Michel A.Gagnon, 3709, avenue Grey, Montréal, tous six avocats, et André Guertin, commis, 222, Lacharité, LaSalIe.pour les objets suivants: Exploiter uni* agence «le spectacles, sous le nom de « I,e Théâtre «le la Place Ville-Marie inc.», avec un capital total «le $40,000.divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listrict jmlieiaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 6e jour «le mai 1964.Le Sous-secrétaire de la produce, Raymond Douvillk.6969-o 1986-64 Le Théâtre de la Place Ville-Marie Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 6th day of May.1064, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, incorporating: P.-Wilbrod Gauthier, 1985 Belle vue Ave.St-Bruno, Pierre Legrand.415 Place «l'Amiens, Duvernay, Pierre Cimon, 12 «le Provence St., Préville, L.-Yves Portier, 40 Arlington, Westmount, Raymond Crevier, 245 Outremont Ave., Outremont, Michel A.(iagnon, 3768 Grey Ave., Montreal, all six advocates, ami André Guertin, clerk.222 Lacharité, LaSalle, for the following purposes: To operate a theatrical agency, umler the name of \"Le Théâtre tie la Place Ville-Marie inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,(MM> common shares «>f a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 6th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969 1086-64 Thetford Marine Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la Thetford Marine Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the llth day of May, 1964, have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 1904, Vol.96, No.25 3325 province de Quebec, des lettres patentes, en «late du He jour de mai 1964, constituant en corporation: Paul-Emile billion, commerçant, 305, rue Carrette, Real Pillion, comptable, 30, rue fabrique, et Evelyne Jolin, ménagère, épouse séparée «le biens de Paul-Emile Roy, 900, 8c avenue, tous trois de Thetford Mines, pour les objets suivants: Faire le commerce de bateaux de toutes sortes, moteurs, instruments de bateaux et tous accessoires, sous le nom de « Thetford Marine Inc.», avec un capital total de 640,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.I.e siège social de la compagnie sera à Thetford Mines, district judiciaire de Mégantic.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce I le jour de mai 1964.Le Saint-neerefaire de la province, Raymond Douvillk.6969-0 2005-01 Township Supply Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Iaù des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 5e jour de mai 1964, constituant en corporation: Jerry Wiseberg, marchand, 675, Davaar, Outremont, Naomi Hughes Hallett, 3375, Ridgc-wood, et Eleanor Rosenthal, 5200, Grenier, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le toutes sortes d'approvisionnements mécaniques, sous le nom «le « Township Supply Corp.», avec un capital total de $40,000.divisé en 1,000 actions Ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $10 chacune.I.e siège social «le la compagnie sera à (iranby, district judiciaire de Bedford.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 5e jour de mai 190)4.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dolvillk.6969 1989-04 been issue»! by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Paul-Emile Fillion, trader, 305 Carrette Street, Real Pillion, accountant, 30 Fabrique Street, and Evelyne Jolin, housewife, wife separate as to property of Paul-Emile Roy, 900, 8th Avenue, all three of Thetford Mines, for the following purposes: To cany on business dealing Ul all kinds of boats, motors, instruments for boats ami all accessories, under the name of \"Thetford Marine Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 250 common shares of $100 each and 150 preferred shares of $100 each.The hea«l office of the company will be at Thetfonl Mines, judicial district of Megantic.(iiven at the office »>f the Provincial Secretarv, this llth day of May, 1904.Raymond Doivillk.Insistant Secret an/ of the Province.090)9 2005-04 Township Supply Corp.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 5th «lay of May, 1904, have been issued by the LicutcnauM lovernor of the Province «)f Quebec, incorporating: Jerry Wiseberg, merchant, 075 Davaar, Outremont, Na«>mi Hughes Hallett, 3375 Ridgcwood.and Eleanor Rosenthal.5200 Grenier, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To deal in all kinds of mechanical supplies, under the name of \"Township Supply Corp.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at (iranby, judicial district of Bedford.Given at the office of the Provincial Secretary, this 5th «lay of May, 1904.Raymond 1)«>i villi:.Assistant Secretary of the Province.6969-0 1989-64 Transex Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 4e jour «le mai 1964, constituant en corporation: Jack L.Greenwood, avocat, 044, Lans-downe, Westmount, Melvin Salmon, avocat, 5570, avenue Pine«lale, Côte-St-Luc, et Marika Strobach, secrétaire, célibataire, 1027, avenue Trait.Outremont, pour les objets suivants: Agir comme traducteurs, agents de publicité, el consultants, sous le nom «le « Transex Ltd.», avec un capital total de $20.000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $5 chacune.I.e siège social «le la compagnie sera 1255, rue I_Diversity, chambre 508, Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce le jour «le mai 1964.//e Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.'\u2022009 1993-64 Les transformations de Québec inc.Quebec Transformers Inc.Transex Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 4th «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jack L.Greenwood, advocate, 044 Lansdowne, West-mount.Melvin Salmon, advocate.5570 Tim-dale Avenue.Côte-St-Luc.ami Marika Strobach, secretary, spinster, 1027 Pratt Avenue.Outremont, for the following purposes: To act as translators and advertising agents ami consultants, umler the name of \"Transex Ltd.\", with a total capital stock of $20.000, divided into 4.000 common shares of $5 each.The hca«l office of the company will be at 1255 University Street.Room 508, Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of May.1964.Raymon d Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969-o 1993-64 Les transformations de Quél>ec ine.Quebec Transformers Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act.letters patent. 8326 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 20 juin 1961 96' année.Jfa*»f été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province f $10,000.divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at 5511 Place St-Donat, Anjou, judicial district «>f Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 5th day of May.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.0909 1925-0) Trottier, O'Brcady & associés inc.Trottier, O'Brcady & Associates Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent bearing date the 14th «lay of May.1904.haw been issued by the Liei:teiiaiit-(Jovernor of tile Province of Quebec, incorporating: André Trottier, Roger Veilleux, both chartered accountant-.Jacques O'Brcady.advocate, all three of 230 King St.West, Sherbrooke, Conrad Tourigny.chartered accountant, 119 Noël.St., Asbestos, and Jaar value of $100 each, 200 preferred class \"A\" shares of a par value of $1 each and 248 preferred class \"B\" shares of a pur value of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 1961>, Vol.96, No.26 3327 Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, «listrict judiciaire «le St-Fran«;ois.Donné au bureau «lu .secrétaire «le la province.ce 14e jour de mai 1064, Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.(1969-0 v 1946.64 Alcidc Trudeau & fils lice Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Quéliee, il a rte accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du Se jour «le mai 1961, constituant en corporation: Alcidc Trudeau, 1071.Belvé«lère, sud, Gilles Tni'leaii.1371, Bienville, et Jean-Claude Trudeau, 1071.Belvédère, sud, tous trois commerçants, «le Sherbrooke, pour les objets sui- .mis; Faire araires comme quincailliers, sous le nom de « Alcide Trudeau & fils ltée ».avec un capital divisé en 1.000 actions ordinaires «le $1 chacune, 500 actions privilégiées classe « A » d'une valeur au pair «le §100 chacune, 1.000 actions privilégiées classe « B » d'une valeur au pair «le 6100 chacune et en 500 actions privilégiées classe « ('» sans valeur au pair OU muni-haie.I onné au bureau du secrétaire «le la province, ce 5e jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.6969-0 1889-64 l m inn provinciale des racketteurs, inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 5th «lay of May.1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Roméo Founder, mechanic, 27 St-Louis, Loretteville.R«-né Couture, civil employee, 10 Côte Labadie, Levis.Louis Langlois, civil employee.320 St-Ansebne, Quebec, Léandre Gaudreau, clerk.1 Papineau, Montmagny.Maurice Sylvain, electrician.2454 Maufils.Quebec.J.-Robert Ouellet.miner.174,8th Street.West.Thetford Mines.Charles Greer, line-man.73 Boiaclair, Quebec, Femand Dupuis, restaurateur.488 «le la Canardièrc.Queliee.Louis-Philippe Rathel.civic employee.401 Ste-Thérèse.Quebi'c, George Fgan, annuitant.721 d'Aiguillon.Quebec.Paul Jobidon, watchman.1050 Champfleury.Quebec, Marcel Vermette.labourer.046 Bagot.Quebec, Henri-Paul Papillon, civil employee.403 St-Claude, Neufchfttel, and Fernahd Alain, chauffeur, 412 Napoléon.Quebec, for the following purposes: To promote the sport of snow-shoeing, under the name of \"Union provinciale des nupietteurs.inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $25.000.The head office of the corporation will lie at Quebec, judicial «listrict of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 5th day of May, 1964.Raymond Dou villk, Assistant Secretary of the Prorince.6969 1889-64 3328 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 1964, 96' année.No 25 GlllM Veilleux ltée Avis est donné Qu'on vertu (le la première partie «le la l-oi «les compagnies «le Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettre* patentes, en «late «lu 1er jour «le mai 1904, constituant en corjH)-rati«>n: Gilles Vei lieux, plombier.Colombe Veilleux, ménagère, éjMMise contractuellement séparée «le biens «liulit Cilles Veilleux, tous «leux «le 90S, b«)ulevar«l St «-Thérèse, et .1.-Arthur Savanl, comptable, 608, rue «les Pins.tous trois «le Dolbeau, pour les objets suivants: ^ Exercer le commerce d'entrepreneurs en plomberie, f Quebec, incorporating: Joseph Roy Hoffman, advocate ami Queen's Counsel, 4918 Mayfair, Montreal, Oscar Respitz, advocate, 4945 Glencairn, Montreal, and Sydney B.Sederoff, advocate, 80 Crestwixnl, Montreal West, for the following purposes: To manufacture ami «leal in paper ami paper products, umler the name of \"Ville Marie Paper Rox Co.Ltd.**, with a total capital stock of $20,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The heae at 888 Ray Circle, St-Laurent, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 1904, Vol 90, No.25 3329 Donné au bureau du secretaire de la province, ce 12e jour de mai 1904.Le Sou.s-.wrfluire Je la province, Raymond Douvillk.2121-04 Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of May, 1904.Raymond Doivillk, Assistant Secretary at the Province.0909-o 2121-04 Zodiac ltée Zodiac Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il u été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du Sic jour de mars 1904, autorisant la fusion de « Zodiac inc.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du f) décembre 1902, et «Canada flooring Limited», constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 31 octobre 1063, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de placements et de gestion, sous le nom de « Zodiac ltée Zodiac Ltd.».avec un capital total de 63,300,000, divisé en 150,000 actions classe « A » d'une valeur au pair de $20 chacune et en 00,000 actions classe « B » d'une valeur au pair de 66 chacune.Le non de la nouvelle compagnie est « Zodiac ltée - Zodiac Ltd.» Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 31e jour de mars 1964.Le Sous-secrétaire Je la province, Raymond Doivillk.6069*0 1543-04\u2014 1219/110 Zolov Productions Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour d'avril 1964, constituant en corporation: Judah Lyon Wolofsky, avocat, 4165, Esplanade, Montréal, Rernard Robert Renson.avocat, 652, Lansdowne, Westmount, et Anne Granofsky, secrétaire, épouse séparée de biens de Benjamin Neaman.4825, avenue Maple wood, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de productions pour la radio, la télévision, le cinéma et la publicité, sous le nom de « Zolov Productions Inc.».avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune et 35,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1235, rue Crescent, chambre No 3, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour d'avril 1964.Le Set» secrétaire Je la province, Raymond Douvillk.0900 1870-64 Zodiac ltée Zodiac Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 31st day of March.1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of QucImtc.authorizing the amalgamation of \"Zodiac inc.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies Act.by letters patent of December 5.1962.and \"Canada Flooring Limited\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies Act.by letters patent dated October 31.1063, for the following purposes: To carry on the Operations of an investment and managing company, under the name of \"Zodiac ltée Zodiac Ltd.\".with a total capital stock of 63,300,000, divided into 150.000 class \"A\" shares of a par value of $20 each and into 60,000 class \"B\" shares of a par value of $5 each.The name of the new company is \"Zodiac ltée Zodiac Ltd.\" The head oflice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 31st day of March.1964.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.6969 1543-64\u2014 1219/110 Zolov Productions Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of April, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Judah Lyon Wolofsky, advocate, 4165 Esplanade, Montreal.Bernard Robert Renson.advocate.652 Lansdowne, Westmount, and Anne Granofsky, secretary, wife separate as to property of Benjamin Neaman, 4825 Maplewood Avenue, Montreal, for the following purposes To deal in radio, television, cinema and publicity productions, under the name of \"Zolov Productions Inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 5,000 common shares of $1 each and 35,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at 1235 Crescent Street.Room No.3, Montreal, judicial district of Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of April.1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969-o 1870-64 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent A.C.I.Property Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la A.C.I.Property Corporation Notice is hereby given that, under Part 1 of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, hearing date the 13th day of May, :muth Shore Packing Inc.\", incorporated by letters patent dated the 12th day of October, 1956, changing its name to that of \"Au Petit Oorct inc.\".(iiven at the office of tin- Provincial S«-cretary.this 2Sth «lay «>f May, 1904.RayMOMo Douvillk.Assistant Secretary of the Province.0909 .3207-56 \u2014 1220/17 Authentichronie inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late du 0e jour de novembre 1963, à la compagnie « ( .'olor ( 'atalogue ( 'reators Ltd.».constituée par lettres patentes en «late du 3e jour de février 1901, changeant son nom en celui de « Authentichronie inc.».Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 28e jour «le mai 1ÎXV4.Le Sous-sécrétaire de la province, Raymond Douvillk.0909 10001-61 \u2014 1220/18 Cela Corporation Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 14e jour «le mai 1904, à la compagnie « Cela Corporation Limited », modifiant les privik'ges et restrictions attachés aux actions privilégiées.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 14e jour «le mai 19(54.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.0909 13757-01 \u2014 1219 I lit Authentichroine inc.Notice is hereby given that, umler Part 1 «>f the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing date the 0th «lay of November, 19(53, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «»f Quebec, to \"Color Catalogue Creators Lt«L\".incorporated by letters patent dated the 3rd «lay «>f Pebruary, 1901, changing its name to that of \"Autheutichrome inc.\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of May.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.0909-o 10(501-61 \u2014 1220/18 Cela Corporation Limited Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing «late the 14th «lay of May, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Cela Corporation Limited\", mollifying the privileges ami restrictions attaching to the preferred shares.(iiven at the office «>f the Provincial Secretarv, this 14th .lay of May.1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the I'rorince.09(59-o 13757-01 \u2014 1219/119 Collège Marie dc France Avis est donné qu'en vertu «les dispositions «le la Ix)i des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 15e jour «le mai 1964.à la corporation « Collège Marie de France ».étendant ses pouvoirs.Collège Marie de France Notice is hereby given that, umler the provisions of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 15th «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Collège Marie de France\", extending its powers. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 1961 Vol.96.So.25 3331 Donné au bureau du .secrétaire de la province, ce 15e jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.09(59-0 3212-39 - 1220/49 Crédit M.-G.inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 28e jour de février 1904, à la compagnie « Crédit M.-G.inc.», confirmant son règlement numéro 4 constituant un compromis ou arrangement entre ladite compagnie et les détenteurs «le m actions classe «< A » et classe « R », relativement au changement des droits, privilèges et restrictions alférents auxditcs actions classe « A » et classe « 11 ».Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 28c jour «le février 1964.Le Sous-secrétaire île la prorince.Raymon i» Douville.16276-69 \u2014 1219/80 6909-o Le* Entreprises Bouclier ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 21e jour d'avril 1904.à la «compagnie « Sheficld Investment Corp.», constituée par lettres patentes en «late «lu 20e jour de mai 1959, changeant son nom en celui de « Les Entreprises Rouclier ltée ».Donné au bureau du secrétaire «le la province, 08 21e jour d'avril 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.0909 13007-59 \u2014 1220/25 Équipement de buanderie et de nettoyage à sec International limitée International Laundry & Dry Cleaning Equipment Limited Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 9e jour «l'avril 1904, à la compagnie « International Laundry & Dry-Cleaning Equipment Limited », constitute par lettres patentes en date «lu 2tie jour «le février 1964, changeant son nom en celui «le « Equipement de buanderie et de nettoyage à sec International limitée \u2014 - International Laundry & Dry Cleaning Equipment Limited ».Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 9e jour d'avril 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.690!) 949-64 \u2014 1220/26 (iiven at the office of the Provincial Secretarv, this 15th f February, 1964.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Prorince.6969 16276-69 \u2014 1219 80 Les Kntreprises Rouclier ltée Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing date the 21st «lay of April, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Shcfield Investment Corp.\", incor|x>ratcd by letters patent dated the 20th «lay of May, 1959, changing its name to that of \"Les Entreprises Rouclier ltée\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of April, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.0969-o 1*3007-59 ~ 1220/25 Équipement de buanderie et de nettoyage h sec International limitée International Laundry & Dry Cleaning Equipment Limited Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of April.1964, have been issued by the Lien tenant Governor of the Province of Quebec, to \"International Laundry & Dry Cleaning Equipment Limited\", incorporate*! by letters patent date«I the 26th «lay of February, 1964, changing its name to that of \"Équipement de buanderie et de nettoyage à sec International limitée \u2014¦ International Laundry & Dry Cleaning Equipment Limite*!\".(iiven at the office of the Provincial Secretarv, this9th «lay «)f April.1964.Raymond Douvillk, Assistunt Secretary of the Province.6969-o 949-64 - 1220/26 Federal de.LoUir» - Dau*.du Québec Fédératiou de» L.Uir.-Dause du Québec Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 20e jour d'avril 1964, à la corporation « Fédération Folklorique du Québec inc.», constituée en vertu des dispositions de la troisième partie de ladite Loi «les compagnies de Notice is hereby given that pursuant to the provisions of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th day of April, 1964.have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Fédération Folklorique «lu Québec inc.\", incorporate*! under the provisions of Part III of the said Quebec Companies Act.by letters patent 3332 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 20 juin 19(4, 9(>> année.No 25 Québec, pur lettres patentes en date du 0 avril 1901, changeant son nom en celui de « Fédération des lx>isirs - Danse du Québec ».Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour d'avril 1064.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.0900-o 11760-61 - 1219/51 Finance Mercantile inc.Mercantile Finance Ine.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 24e jour d'avril 1964, à la compagnie « Mercantile Finance Corporation Ltd.».Constituée par lettres patentes en date du 21e jour de septembre 1954, changeant son nom en Celui «le « Finance Mercantile inc.Mercantile Finance Inc.».Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 24e jour «l'avril 1964./, Nord-Est par une autre partie «lu lot numéro 83.vers le Sud-Kst par une partie du lot numéro 84.ci après décrite, vers le Sud-Ouest par le chemin Chambly.Mesurant trois cent «piatre-vingt-trois pieds cl six dixièmes «le pied (383.0') de largeur sur des profondeurs «le «leux cent cinquante meds (250.0') lans les lignes Nord-Ouest et Sml-Est.Contenant en superficie quatre-vingt-quinze mille neuf cents pieds carrés (96,900.00.< et te partie du l«>t numéro 84, des plan et livre de renvoi officiels «le la paroisse «le St-Iluhert, bornée vers le Nord-Est par une autre partie du lot numéro 84.vers le Sud-Est par une partie du lot numéro 93 («lu cadastre officiel «le la paroisse St-Joseph de Chamhly), vers le Sud-< hiest par le chemin ( 'hamhly, vers le Xonl-Ouest par une partie du lot numéro 83 ci-haut décrite.Mesurant Sept cent soixante-sept pieds et «leux dixièmes «le pied (707.2') «le largeur sur «les profondeurs «le «leux cent cinquante pieds (250.0') dans les lignes Nord-Ouest et Sud-Est.Contenant en superficie cent quatre-vingt-onze mille huit cent pietls carrés (191,800.0').Cette partie du lot numéro 85, «les plan et livre «le renvoi officiel «le la paroisse «le St-Huhert, hornée vers le Nor«l-Est par le chemin Chamhly, vers le Sud Est par une partie «lu lot numéro 105 (du cadastre officiel «le la paroisse St-Joseph de Chamhly), vers le Sud-Ouest par une autre partie du lot numéro 85, vers le Nord-Ouest par une partie du lot numéro 80 ci-après «lécrite.Number 1075 Quebec, June 3.191 il.Present: The Lieutenant-Governor in Council.concerning the declaration of an \"arrondissement historique\" in Quebec.WHEREAS at a meeting of the Quebec Historic Monuments Commission, held at 1530 «le l'Entente Blvd., Quebec, on April 11, 1904.at nine 0'doek in the forenoon, the Historic Monuments Commission decided t«> request the Lieutenant-Governor in Council to declare \"Arrondissement historique\" that part of the municipality of the parish «>f St-Joseph «le Chambly hereinafter describe*!: Whereas ¦ copy of the recommendation of the Commission was transmitted to the Secretary of this municipality on April 17.1964; WHEREAS a notice of this recommendation was published in the Quebec Official C-azttte on April 25, 1904.umler number 039 l-o and on pages 2371.2372 and 2373 of the said Cazctte.It is ordered, therefore, upon the reconunen* dation of the Minister «>f Cultural affairs: That that part of the municipality of Saint-Joseph «le Chambly hereinafter described be declared an \"Arrondissement historique\", to wit: \"That part of lot number 83 in the official plan and book «>f reference of the parish of St-Ilubert, bounded on the northwest by lot number 82, on the northeast by another part of lot number S3, on the southeast by a part of lot number 84 hereinafter described, on the southwest by ( hainbly Bond.Measuring three hundred ami eighty-three ami six-tenths feet (383.60 in width by depths of two hundred and fifty feet (250.0') on its northwest and southeast lines.Having an area «»f ninety-five thousand nine hundred square feet (95.900.0').That part of lot number S4 in the official plan ami hook of reference of the parish of Bt-Hubcrt, bounded on the northeast by another part of lot number 84, on the southeast by a part of lot number 93 (in the official cadaster of the parish of St-Joseph de Chambly).on the southwest by Chambly Koad.on the northwest hy a part of l«)t number 83 described above.Measuring seven hundred ami sixty-seven and two-teath feet (707.2') in width by depth of two hundred and fifty feet (250.0') on its northwest and southeast lines.Having an area of one humlred and ninety-one thousand eight hundred square feet (191.S00.0').That part of lot number 85, in the official plan and book of reference of the parish of St-Hubert, bounded on .the northeast by Chambly Koad, on the southeast by a part of lot number 105 (in the official cadaster of the parish of St-Joseph «le Chambly), on the southwest by another part of lot number 85, on the northwest by a part of lot number SO hereinafter described. 3340 ' OMETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 1904, 96' année, Xo 25 Mesurant deux cent quarantf-dnq pieds (245.0') dans lu ligne Nord-Est, trois «'eut cinq pieds (305.0'; dans la ligne Sinl-Ouest.Deux cent cinquante pieds (250.0') dans les lignes \\ord-Ouest et Sml-Est.Contenant en superficie cinquante-cinq mille huit cent soixante-douze pieds carres (55,872.0*)- Cette partie du lot numéro 86, des plan et livre de renvoi officiels del a paroisse de St-IIuhcrt, bornée vers le Nonl-Kst par le Chemin Chainhly.vers le Sud-Kst par une partie du lot numéro 85 ci-haut décrite, vers le Sud-ouest par une autre partie du lot numéro 86, vers le Nord-Ouest par une partie du lot numéro 87.Mesurant cinq cent soixantc-quin/.c pieds et quatre dixièmes de pieds (575.4') de largeur sur des profondeur* de deux cent cinquante pieds (250.0') dans les lignes Nord-Ouest et Sud-Kst.Contenant en superficie cent quarante-trois mille huit cent cinquante pieds carrés ( I I3.s50.0').Cette partie du lot numéro 87, des plana et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-IIuhcrt.bornée vers le Nord-Ouest par le lot numéro 88, vers le Nord-Kst par le Chemin Chainhly, vers le Sud-Kst.par le lot numéro86, vers le Sud-Ouest par une autre partie du lot numéro S7.Mesurant cinq cent soixante-quinze pieds et quatre dixièmes de pied (575.4') «le largeur sur des profondeurs «le deux cent cimpiantc pieds (250.0') dans les lignes Nord-Ouest f reference f«> the parish of St-Hubert, bounded on the northeast by Chambly lb.ad.on the southeast by a part of lot number 85 described above, on the southwest by another part f one hundred ami ten thousaml one hundred ami ninety square feet (110.190.00.That part of lot number 94, in the official plan and book «>f reference of the parish of St-Jascph «le ( \"hninbly.bounded on the northeast by a part of l«>t number 94.on the southeast by-lots numbers 95 and 96, «>n the southwest by Chambly Road, on the northwest by a part of lot number 93 described above.Measuring ninety-nine feet (99.00 in width by a depth of two hundred and fifty feet (250.0') on its northwest ami southeast lines.Having an area of twenty-four thousand seven hundred ami fifty square feet (24,750.0').That part of lot number 105.in the official plan an«l book of reference of the parish of St-Joseph de Chambly, bounded on the northeast by Chambly Road, on the southeast by lot number 106, on the southwest by another part of lot number 105, on the northwest by lot number 85 (in the official cadaster of the parish of St-Hubert).Measuring five hundred and seventy-five and four-tenths feet (575.4') in width by depth of two hundred and fifty feet (250.00 on its northwest and southeast lines. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 19l'4.Vol.96, So.Jo Contenant en superficie cent quarante-trois mille huit cent cinquante pieds carrés ( 143,850.0').Lai mesures données dans la présente description technique sont en mesures anglaises.Jacqies PrÉMONT, ii098-o Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.Arrêté en conseil Chamhre du Conseil Exécutif Numéro I 153 Section « B » Québec.10 juin 1964.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil CONCERNANT la prolongation du droit de prélèvement du Comité paritaire des Coiffeurs pour daines de Hull.Il kst ORDONNÉ, sur la proposition de Phono rable Ministre du Travail: QrE le droit «le prélèvement «lu Comité paritaire «l«?s Coiffeurs pour dames «le Hull, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 904 (D) «lu 4 juin 1903, soit prolongé jusqu'au 13 septembre 1964, aux mêmes taux et conditions.Jacques.Prémont, 7007-o Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1153 Section « C » Québec.10 juin 1904.Présent: Le lieutenant-gouverneur en coaseil.CONCBRNANT la prolongation du «lécret relatif au métier «le coilfeurs pour dames «lans la région «le Hull.II.kst ORDONNÉ sur la proposition «le l'honorable Ministre du Travail: Que le «lécret numéro 540 (C) du 4 juin 1959, relatif au métier de coiffeur pour dames «lans la région de Hull, soit prolongé jusqu'au 13 septembre 1904.Jacques Peémont, 7007-o Greffier Adjoi-it du Conseil Exécutif.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1153 Section iDl Québec, 10 juin 1964.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.< 'onckknant des modifications au décret relatif aux métiers de barbier et coiffeur dans la région de St-.Iean et Iberville.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amen-demenls), les parties contractantes à la conven-tion colleetive de travail relative aux métiers de barbier et coiffeur dans la région de St-.Iean.rendue obligatoire par le décret numéro 666 du 15 juin 1955 et amendements, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret: Having an area of one hundred and forty three tin.usa ml eight hundred and fifty square feet (143.850.0').All the dimensions in the present technical description are in English measure.Jacques Prémont.0998 Associate Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chumhcr Number 1153 Section \"IS\" Quebec, .lune 10, 1964.Present: The Lieutenant-Governor in Council.concerning an extension of the right to levy of the Parity Committee of the Ladies' Hair-«lressing Trade of Hull.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the right to levy of the Parity Committee of the Lathes' Hainlressing Trade of Hull, authorized by a by-law approved by Order in Council number 904 (!)) du 4 juin 1903, l>e exten-de«l until September 13, 1904.with the same rates and conditions.Jacques Pbemont, 7007-o .tssociate < 'lerk of the Executive ( 'ouncil.Order in Council Executive Council Chamber Number 1153 Section \"C\" Quebec, dune 10.1904.Present: The Lieutenant-Governor in Council.CONCERNING an extension of the decree relating to the ladies' hainlressing t rat le in the region of Hull.It is ordereo, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the decree number 540 (C) of June 4, 1959, relating to the ladies' hainlressing trade in the region of Hull, be exten«le«l until September 13, 1964.Jacques Prémont, 7007-o Associate Clerk of the Executire Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 1153 Section \"D\" Quebec, June 10, 1964.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments to the decree relating to the barbering and hainlressing trades in the region of St-.Iean an«l Iberville.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 103 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the barbering and hairdressing trades in the region of St-.Iean, rendered obligatory by the decree number 666 of June 15, 1955 and amendments, have petitoned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the said decree; 3342 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, $0 juin 1964, 96* année.So 25 Aïtkmm QUE ladite requête a été publiée e dans un délai raisonnable, ap es avis éprit.\u2022Iacqi'kk Pkkmont, ti!i?7-o Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.Arrêté en conseil , Chambre du Conseil Exécutif N uméro 11 50 Québec, le 12 juin 1964.Présent: Lé lieutcnant-g«»uverneur en conseil (onckknant le poids maximum des camions Ii.kst ou donné.but la proposition «le l'honora-ble ministre «les transports et communications, ce qui suit: Kn vertu «le l'article 40 «lu Code «le la Route (Statuts refondue, 1941.chapitre 142.et amen- (I.mente), la modification suivante est apportée aux règlements relatifs à la circulation lourde gui les chemins publics «le la province de Québec décrétés par l'arrêté en conseil numéro 1045 du 27 mai 1904 et.en conséquence, l'alinéa suivant «\u2022>-i inséré avant celui intitulé: « Véhicules extra lourds »: Camions à deux ou trois essieux enregistrés (vaut le premier juin 1961,.be poids total sur un quelconque des essieux pourra excéder «le cinq mille (5,000) livres celui fixé, pour chaque classe de chemins, par l'arrêté en conseil numéro 1045 du 27 mai 1964 et la pesanteur totale, y compris la charge du véhicule, pourra excé«ler, dans la mesure suivante, celle qui a été établie, pour chaque classe de chemins, pu ledit arrêté en conseil numéo 1045: a) camion à «leux (2) essieux \u2014 cinq mille er 1045 of May 27, 1964 ami the total weight, including the load of the vehicle, may exceed, according to the following measure, that which was established, for each class of roads, by the said order in council number 1045; a) two axle truck (2) - five thousand pounds (5.000); : 6) three axle truck (3) - ten thousand pounds (10,000).The present provision applies only to trucks registered in the Province before June first, 1904 and shall be in force until I)eceml>cr 31, 1964.at which time the general provisions of order in council number 1045 shall again apply.\" Jacques Prémont, 7027 Associate Clerk of the Executive Council.Miscellaneous notices Maple Avenue Baptist Church Notice is hereby given that \"Maple Avenue Baptist Church, a Baptist Congregation having its place of worship at Maple Avenue, Browns-burg, P.Q., shall apply to the Lieutenant-Governor in Council for incorporation under the name of \"Maple Avenue Baptist Church\" in conformity with the provisions of chapter 311 R.S.Q.1941.\" Hutcheson, Johnston & Todd, 6780-22-5-o By: J.E.Todd. 8846 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 1964, 96' année, \\o $6 Compagnie autorisée à faire des affaires Company Licensed to do Business I.ianita-Anstalt Avis est donné que « Lianita-Anstalt », une compagnie ù fonds social étrangère constituée en corporation en vertu des lois du Liechtenstein, a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Quéhec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères, Statuts refondus de Quéhec.1941, chapitre 279.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures exercées contre ladite compagnie, est M.Santo Aiello, 5350, rue Jean-Talon, est, Saint-Léonard.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province sera établi à 5350, rue Jean-Talon, est, en la ville de Saint-Léonard, district judiciaire tie Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 5 juin 1964.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Dokviu.k.6969-0 15-64 - 1221/138 Lianita-Anstalt Notice is hereby given that \"Lianita-Anstalt \", an extra-provincial company incorporated umler Liechtenstein laws has been licensed to carry on business in the province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes of Quebec, 1911, chapter 279.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the said company is Mr.Santo Aiello, 5350.Jean-Talon St., east, Saint-Léonard.The principal office of the said company in the province will be established at 5350, Jean-Talon St., East, in the town of Saint-Léonard, judicial district of Montreal.(iiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 5th day of June, 1964.Raymond Dor vii.i.k.Assistant Secretari/ of the Province.6969 \" 15-64 \u2014 1221/138 Chartes - Abandon de Charters \u2014 Surrender of Campobcllo Corporation Avis est, par les présentes, donné «pu- la compagnie « Campobello Corporation », a l'intention de s'adresser au Secrétaire de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.New York, N.Y., le 11 juin 1964.Le Secrétaire, 697l-o Jamks T.Dkvanky.Campobello Corporation Notice is hereby given that 'Caiupobeilo Corporation\", intends to apply to the Provincial Secretary for the Province of Quebec for leave to surrender its charter in accordance with the provisions of the Quebec ( 'ompanies Act.New York, N.Y.June 11.1964 Jamks T.Dkvanky.697 l-o Secretari/.Jeffrose Ltd.Prenez avis (pie la compagnie « Jeffrose Ltd.».compagnie incorporée selon la Loi des compagnies du Quéhec et dont le bureau chef est situé à Montréal, P.Q., demandera au secrétaire provincial, la permission d'abandonner sa charte, selon les prévisions de la I/>i des compagnies «lu Quéhec.Daté à Montréal, ce 10e jour de juin 1964.Le Secrétaire légal, 6972-o J.Roy Hoffman', q. surrender its charter, pursuant to the provisions of the Quebec Companies Act.Dated at Montreal, this eleventh day of June.1904.( 'uisine Sales Corp., (Seal) Leonard Kirsch, 6086-0 Secretary-Treasurer.2277 Joliette Inc.I pou a motion duly approved it is uuani- ¦lousiv resolved: To apply to the Attorney General ami to the Provincial Secretary to accept the surrender of its charter, the onler its cancellation and to fix a «late from ami after which the company shall be dissolved; To authorize the President and the Secretary1 of the company to take the necessary means and to sign the required documents to obtain the surrender of the charter.Certified true copy t)f a resolution adopted by the totality of the shareholders of \"2277 Joliette Inc.\", at their special general meeting held on the 8th day of June, 1904.Norbbbt Dubois, 2987 Secretary.Home Town Construction Ltd.Notice is hereby given that \"Home Town Construction Ltd.*, having its head office in the city of Montreal, province of Quebec, will make application for leave to surremler its charter, in accordance with the provisions of the Quebec Companies' Act.Montreal.June 11.1904.Lawrence Capblovitch, .tttorney for 7000-o Home Town Construction Ltd.The Cradoek Simpson Company Under the provisions of the Quebec Companies Act, \"The Cradock Simpson Company\", hereby gives notice that it will make application to the Provincial Secretary for leave to surremler its charter.Dated at Montreal, April 27.1964.Alan C.Simpson.7001 President.Grande-Allée Construction Limitée Notice is hereby that \"Gramle-Allee Construction Limitée\", a corporation incorporated umler the Quebec Companies Act and having its head office in the city of Ste-Foy, will apply to the Provincial Secretary of the Province of Quebec for leave to surremler its charter umler the provisions of the Quebec Companies Act.Dated at Montreal, P.Q.this 6th «lay of June, 1961.Malcolm J.McLkod.7009-«> Secretary.Treasurer.Garage Ceo.-Henri Moreau Inc.Prenez avis que la compagnie « Garage Geo.-Henri Moreau Inc.», corporation constituée sous la Loi des Compagnies de Québec et ayant son Garage Geo.-IIenri Moreau Inc.Take notice that the company \"Garage Geo.-Henri Moreau Inc.\", incorporated under the Quel>ec Companies Act ami having its head 3348 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 90 juin 1961 90' année.No 26 siège social à St-Apollinaire, eointé «le l.othi nière, P.Q., a ahaiii des compagnies de Québec, M at uts refondus «le Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi, il a plu au secrétaire de la province «l'accepter l'abandon «le la charte i «les compagnies «le Québec par lettres patentes en date «lu 27 avril 1959.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 juin 1964, ladite compagnie a été dissoute.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 16 juin 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.6969m 12400-59 Famous Enterprises Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, section 20, chapter 26, chapter 270, H.S.Q., 1941.ami subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Famous Enterprises Ltd.\", incorporate 14386-53 276, R.S.Q., 1941, ami subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surremler of the charter of the company \"Lanar Development Inc.\", incorporated under said Part I, of the Quebec Companies Act, by letter-, patent dated July 6.1959.Notice is also given that from and after June 15, 1964, the said company has been dissolved.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, on June 16, 1964.Raymond Doivillk, Assistant Secretari/ of the Province.6909 13592-Ô!! Montreal Steam Corporation Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 270, R.S.Q., 1941.ami subject to the liability enaetetl by section 27 of the said Act.the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Mont real Steam Corporation\", incorporated under said Part.I, of the Quebec Companies Act, by letters patent dated April 0.1959.Notice is also given that from and after June 15.1904, the said company has been dissolved.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, on June 10, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretari/ of the Province.0909 10770-5!» Quebec Freeholds Limited Notice is hereby given that under Part I «>f the Quebec Companies Act.section 26, chapter 276, R.S.Q.1941.ami subject to the liability enacted by section 27 of the sai«l Act.the Provincial Secretary has been pleased to accept the surremler of the charter of the company \"Quebec Freeholds Limited\", incorporât «\u2022«! umler said Part I.of the Quebec Companies Act.by letters patent dated July 10.1953.Notice is also given that from and after June 15.1964.the said company has been dissolved.(iiven at the office of the Provincial Secretarv.on June 16^ 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969 14386-53 Rimlac Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la l^oi des compagnies «le Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité «lécrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte «le la compagnie « Rimlac Limited », constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi «h» compagnies «le Québec par lettres patentes en date du 21 juin 1962.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 juin 1964, ladite compagnie a été dissoute.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 16 juin 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.6969-0 12691-62 Rimlac Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surremler of the charter of the company \"Rimlac Limited\", incorporated under said Part I, of the Quebec Companies Act, by letters patent dated June 21, 1962.Notice is also given that from am! after June 15, 1964, the said company has been dissolved.Given at the office of the Provincial Secretary, on June 16, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6969 12691-62 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 1964.VU.96, No, 2ô 3351 Slips l.iniili f Part I of the Quebec Companies Act, section 20.chapter 276, R.S.Q., 1941, ami subject to the liability enacted' by section 27 of the said Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Vanasse Quebec Mines Limited\" (No Peronal Liability), incorporated under said Quebec Mining Companies Act, by letters patent dated January 4th, 1957.Notice is also given that from and after June 15, 1964, the said company has been dissolved.Given at the office of the Provincial Secretary, on June 16, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Prorince.6969 10052-57 Divers Compagnies Cam poind I o Corporation Sommaire du règlement spécial « .1 » Le règlement spécial « A » «lécrété par les administrateurs «le « Campobello Corporation », le 1 le jour de juin 19(54 et ratifié subséquemment à une assemblée générale spéciale des actionnaires de ladite compagnie tenue à la même «late, pourvoit à la distribution «le tout l'actif et biens de la compagnie au pro rata entre ses actionnaires «'t, cette distribution étant faite, à la dissolution de la compagnie et l'abandon de sa charte.New York, N.Y., le 11 juin 1964.Le Secrétaire, (597 l-o James T.Dkvanky.Miscellaneous Companies Campobello Corporation Summary of special by-law \"A\" Special by-law \"A\" enacted by the directors of \"Campobello Corporation\", on the llth day of June, 1964 ami subsequently ratified at a special general meeting of the shareholders of said company held on the same «late.provides for the distribution of all assets and property of the company raleably among its shareholders and, upon such distribution being made, the dissolution of the company ami the surrender of its charter.New York.N.Y.June 11, 1904.697l-o Jambs T.Dkvanky, Secretary.British American Enterprises Ltd.Avis est donné que la compagnie « British American Enterprises Ltd.», a diminué de 7 à 4 le nombre de ses directeurs.Le Secrétaire, Saul Finksilveu.0978 11589-58 British American Enterprises Ltd.Notice is hereby given that \"British American Enterprises Ltd.\", has changed the number of its directors from 7 to 4.Saul Finksilvkr, Secretary.6978-0 - 11589-58 3352 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 20 juin 19GJL, 9C>' année.No 25 College Marie de France Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 8 juin 1964, approuvé les amendements aux règlements numéros 3 et 5 du « Collège Marie de France », et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de lu I^oi «les compagnies de Quéhec.Donné au hureau du secrétaire de la province, ce 10 juin 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.6079-0 3212-39 The Executive Development Institute Avis est donné «pie l'honorable secrétaire de la province a, le 8 juin 1904, approuvé les règlements généraux de \"The Executive Development Institute », et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a «le la Loi des compagnies «le Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 10 juin 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.6980-o 12277-55 College Marie de France Notice is hereby given that the Provincial Secretary has, on June 8, 1964, approved the amendments to by-laws numbers 3 ami 5 of \"College Marie «le France\", ami such, pursuant to the provisions of section 225a of the Quehec Companies Act.(iiven at the office of the Provincial Secretarv, on June 10, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6979 3212-30 The Executive Development Institute Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has.on June 8, 1964.approved the general by-laws of \"The Executive Development Institute', and such, pursuant t the provisions of section 225a of the Quebec Companies Aet.(Jiven at the office «>f the Provincial Secretarv.on June 10, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6980 12277-55 The Executive Development Institute Avis est donné que « The Executive Development Institute », a changé le nombre «le ses directeurs de 12 à 18.Le Secrétaire, J.K.Allison.6980 12277-55 The Executive Development Institute Notice is hereby given that \"The Executive Development Institute\", has changed the number of its «lirectors from 12 to 18.J.K.Allison, Secretary.6980-o 12277-5.'.Moe Herscovitch & Sons Inc.Avis est donné que « Moe Herscovitch & Sons Inc.», a changé le nombre de ses directeurs de 3 à 4.Le Secrétaire, ROBKRT HaKKY HaRTK.6981 8714-53 Moe Herscovitch & Sons Inc.Notice is hereby given that \"Moe Herscovitch & Sons Inc.\", has changed the number of its directors from 3 to 4.ROBKKT HAKKY HARTE, Secretary.698 l-o 8714-5.Î Hôpital S te-Rose Avis est donné que le secrétaire de la province, a, le 9 juin 1964, approuvé le règlement numéro 33 de l'« Ilûpital Ste-Rose ».et ce, conformément aux dispositions «le l'article 225 «le la Loi «les «compagnies de Québec.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 11 juin 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.6982-o 13489-57 N.Laurin et Fils limitée Avis est donné que la compagnie « N.Laurin & Fils limitée », a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le Secrétaire, Rita Larociikllk Laurin.6983-o 995-34 Modern Neon Sign Co.Ltd.Avis est donné que la compagnie « Modern Neon Sign Co.Ltd.», a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le Secrétaire, Louis Dkhrociies.6984-o 43661-53 Hôpital Ste-Rose Notice is hereby given that the Provincial Secretary has, on June 9.1964, approved by-law number 33 of \"Hôpital Ste-Rose\", and such, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act.(iiven at the office of the Provincial Secretary, on June 11, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.6982 13489-57 N: Laurin et Fils limitée Notice is hereby given that \"N.Laurin & Fib limitée\", has changed the number of its directors from 3 to 4.Rita Lahociikllk Laurin.Secretary.6983 995-34 Modern Neon Sign Co.Ltd.Notice is hereby given that \"Modern Neon Sign Co.Lt«l.\", has changed the number of its «lirectors from 4 to 3.Louis Dk.hhoches, Secretary.6984 43661-53 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 1904, Vol.90, .Vo.25 3858 I f Quebec by letters patent on the 14th day of May 19t>4 ami having its head office in the city of Montreal, has established il s office at number 4855 Bourret Street, in the city «>f Montreal.From ami after the «late of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.(Jiven at Montreal, this fourteenth day of May, 1964.WlKI.and Kaisku.6990-o President.Entreprises B & C Ltée B & C Enterprises Ltd.Avis est donné «pie la compagnie « Entreprises B & C Lree \u2014 B & C Enterprises Ltd.», a été constituée en corporation dans la province de Québec par lettres patentes en «late «lu 5 février 1964.Le siège social de la compagnie est situé au numéro 9164 «le la 57e avenue, à Rivière-des-Prairies, Montréal, et constitue «'-gaiement son principal bureau.Montréal, ce 11 juin 1964.Les Procureurs dûment autorisés des Entreprises B.«{\u2022 C Ltée, 6991-o Chaussk, (JoniN, Dkschknks & Prat.Fonds Adanae Inc.Avis est, par les présentes, donné «pie « Fonds Adanae Inc.», une compagnie dûment constituée en corporation en vertu «l«?s dispositions de la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec* par lettres patentes émises en date du 29e jour «le novembre 1963, et ayant son siège social en la ville de Montréal, province «le Québec, Canada, y a établi un bureau à 132 ouest, rue St-Jacques.À compter «le la «late du présent avis, ledit bureau est considéré, par la compagnie, comme étant son siège social.Donné et signé en la ville de Montréal, province «le Québec, Canada, en date «lu 27e jour d'avril 1964.(Sceau) Is Secrétaire trésorier, 6992-o Sekck Rochki.eau.Entreprises B & C Ltée B & C.Enterprises Ltd.Notice is given that the company \"Entreprise!) B & C Ltée \u2014B & C Enterprises Ltd.\", ».incorporated in the Province of Quebec by letters patent dated February 5, 1964.The head office of the company is situated at number 9164, 57th Avenue, at Rivière-«les-Prairie>.Montreal, ami it is also its main office.Montréal.June II.1964.('llAt'skk, (Jodin, Dkschknks & PltAT, Duly authorized attorneys for 6991 Entreprises BAC Liée Fonds Adanae Inc.Notice is hereby given that \"Fonds Adanae Inc.\", «luly incorporated under Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent bearing «late the 29th day «>f Novemlier 1963, and having its head office in town of Montreal, province of Quebec.Canada, has therein established at 132 St.James St., West.From ami after the «late of the present notice, the said office is considered as being its head office.(Jiven and signed in the town of Montreal.Province of Quebec, Canada, dated 27th dav of April 1964.(Seal) Skkok Rochki.kau, 6992 Secretary-Treasurer.L'Oeuvre des Terrains de Jeux de Mont brun Inc.Avis est donné que la compagnie « L'Oeuvre des Terrains de Jeux de Mont brun Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 28 mai 1964, a établi son bureau dans la ville de Mont brun, district de Rouyn-Noranda.À compter de la date du présent avis, leisie, le long des côtés nord-est, est, des blocs « K », « 1) ».« C », « H », « A ».« F » et « G » du même canton de Moisie, le long «lu côté mini «lu bloc « G », des canttins de Moisie et Letellier et «le la ligne reliant lesdits côtés nord, le long «les côtés ouest et sud-ouest du Idoe « (J », canton Letellier jusqu'au point « () » point d'intersection «lu «\"ôlé sud-ouest «lu bloc « G » avec la limite nord «le la Réserve Cantonale Letellier.De là, suivant une direction générale ouest, le long du côté nord «le la réserve Cantonale Letellier jusqu'à son extrémité ouest, soit le point « F » sur le plan accompagnant cette description.De là.suivant une direction générale nord-ouest, le long d'une droite jusqu'au point « Q » situé à une distance «le 2640 pieds (l ¦> mille) depuis le point le plus au nord «le la rive «l'une baie, elle-même située à l'extrémité nord «lu Grand Lac des Rapides, distance mesurée suivant une direction nord.De là, suivant une direction générale sud-ouest, le long d'une «Imite jusqu'au point « R ».soit l'encoignure nord «lu bloc « M » «lans le canton Arnaud.De là, respectivement par les points « S ».« T ».« l' », « V » et « A », suivant ainsi une partie du côté nord-est «lu bloc « M », les côtés nord-ouest, nord-est, est et sud «lu bloc « N », le cêité sud «lu bloc « M » ainsi «pie son prolongement jusqu'au point «le départ « A ».Dans cette description et sur le plan l'accompagnant, les directions sont approximatives ou générales et les distances en pieds anglais.Ce changement prendra effet pour fins «l'élection, le premier juillet 1964 et pour toutes autres fins, le premier août 1964.Québec.le 16 juin 1964.Le Ministre de l'Education.Paul Gkhin-Lajoik.702 l-o 1666-63 Ste-Anne-dc-la-Pocaticre et St-Onésime Demande est faite; 1° De changer la limite entre la municipalité scolaire de Ste-Anne-de-la-Pocatièrc et la municipalité scolaire de St-Onésime, dans le comté de Thence, following a general north-easterly direction, along a straight line, as far as point \"F\" situated at 2000 feet to the south of the south end of Grande Houle Island.Thence, in a general northerly direction, alon-a line parallel to the east bank of Grande Houle and Fetite Houle islands, and distance by 2000 feet from them, as far as poing \"G\" situated at 2000 feet from the north «>f the mirth end of Fetite Houle Island.Thence, billowing a general westerly direction, along a straight line, as far as point \"II\" situated at a distance of 2000 feet to the southeast of Pointe-su-Bssque, and at 2000 feet, also, t«i the northeast extremity «if Grande Hasipje island Thence, in a general easterly direction, along a line parallel to the shore, at a distance of 200!) feet from the latter, as far as point \"I\" situated at 2000 feet t«i the east «if the point of village of Moisie.Thence, following the center-line of the Moisie River, as far as poing \"J\", which point is the intersection «if the saiil center-line of the river with the extension «if the southeast side of the part of block \"K\" situated on the north side that of \"Stanhope\".Quebec.June 10.1904.Paul Gkiun-Lajoik.7024-25-2 Minister of Education.Ministère du Travail Avis d'approbation de règlements L'honorable Carrier Fortin, ministre «lu Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la Convcul ion-collective (S.K.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que, par l'arrêté en conseil numéro 1153 \u2022lu 10 juin 1964, section «k A », la constitution et les règlements généraux «lu Comité paritaire des barbiers, coiffeurs et coiffeuses du district de Saint-François, approuvés par l'arrêté en conseil numéro 861 «lu 23 juillet 1958 et subséquent-ment amendés, ont été remplacés par «le nouveaux règlements revisés et refondus avec amendements, et le Comité sera désormais désigné en français sous le nom «le: « Le Comité paritaire des coiffeurs «le Sherbrooke ».et en anglais: « Sherbrooke Hairdressers' Parity Committee ».Le Sous-ministre du Travail, Gkkakd Tremblay.Ministère «lu Travail, Québec, le 20 juin 1964 .7007-o Avis Convention collect ire de travail relative à l'industrie de la construction \u2014 Trois-Rivières L'honorable Carrier Fortin, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions «le la Loi «le la convention collective (Statuts refondus «le Québec 1941, chapitre Department of Labour Notice of approval of by-laws The Honourable Carrier Fortin, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that, by Order in Council number 1153 of June 10, 1964, section « A », the constitution and general by-laws of the Barbers and Hairdressers Parity Committee of St.Francis district, approved by Order in Council number 861 of July 23, 1958 as amended, have been replaced by new by-laws, revised with amendments, ami the Parity Committee shall now be named in French: \"Le Comité paritaire «les coiffeurs «le Sherbrooke\", and in English: \"Sherbrooke Hairdressers' Parity Committee, Gkkakd Tremblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 20, 1964.7007-o Notice Collect ire labour agreement relating to the construction industry \u2014 Trois-Rivières The Honourable Carrier Fortin.Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941.chapter 163 8884 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC.20 juin 1961 96* année.So 96 168 ft amemlements), que les parties contractantes ci-après mentionnées lui ont présenté une requête à reflet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: D'une part: La Corporation des Maitrcs-Fdectricieiis de la Province de Québec, section dé Trois-Rivières; L'Association des Constructeurs do la Mauricie Inc.; Et.d'autre i'aht: Le Conseil des Métiers de la Construction de la Cité et de la Région «le Trois-Rivières pour les employeurs et les salariés de l'industrie et dés métiers visés, suivant les conditions ci-après décrites: I.Définition: Aux fins d'application, les mots et termes suivants ont la signification qui leur est ci-après donnée: a) Le terme S entrepreneur S désigne toute personne physique '> morale, société OU corporation, qui travaille seule ou emploie un ou des salariés, qui surveille ou entreprend pour le compte d'autrui, à l'heure, à la journée ou à forfait, par convention verbale, écrite ou autrement, un ou plusieurs travaux visés par le décret.Toutefois, la définition du terme « entrepreneur » dans la Loi concernant les électriciens et les installations électriques (Statuts refondus de Québec.1941.chapitre 172 et amendements) continue de s'appliquer aux entrepreneurs électriciens, pour tous les travaux assujettis au «lécret.b) Le terme « artisan » «lans les métiers «le la construction, comprend toute personne qui exécute habituellement «le ses propres mains un travail faisant l'objet «lu décret, soit à forfait ou autrement, par convention verbale ou «'-crite.Doit être aussi considérée comme artisan, aux fins «lu décret, toute personne physique ou morale, société ou corporation qui construit pour son propre compte une ou «les maisons OU autres édifiées dans un but de vente ou «le spécultion.c) Le terme « apprenti » désigne le salarié qui apprenti l'un ou l'autre «les métiers visés par le décret.d) Le terme « apprenti-électricien » a le même sens qui lui est «lonné «lans la Loi «les Électriciens et des Installations électriques (Statuts refondus «le Québeé, 19-11 chapitre 172 et amendements).t> e) Le terme « compagnon » désigne tout salarié qui a terminé son apprentissage et qui a obtenu sa licence ou son certificat de qualification./) Le terme « compagnon électricien » désigne tout salarié qui détient la licence « C » en exécution «le la Loi concernant les électriciens et les installations électriques (Statuts refondus «le Québec.1941 chapitre 172 et amendements.g) Le terme « compagnon junior » désigne un salarié e au 30 avril «le l'année suivante a droit à la fin «le telle pérhxle.à une vacance d'une durée minimum de sept (7) jours consécutifs.Il recevra comme rémunération de vacances une somme égale à 4% «le SOU salaire brut gagné au service de son employeur./'I Les vacances ainsi prévues doivent être prises «lans une péri«>«le fixée par entente entre l'employé et son employeur, ('epemlant.tout salarié appelé à exécuter «lu travail urgent pendant la semaine «le la vacance annuelle «loit prendre la vacance à laquelle il a «Iroit, la semaine suivante. 4% of his gross earnings with his employer.b) Such vacations shall be taken at a date determined by agreement between the employer and his employee.However, every employee called to execute urgent work in the annual vacation week shall take the vacation week to which he is entitled the following week.c) Every employee governed by the decree, whose work has not been continuous with one employer throughout a vacation-with-pay credit period, is entitled, at the end «>f such period, only to a remuneration equivalent to 4% of his gross earnings.d) At the enil of every week, the employer shall credit every one of his employees governed by the decree with a sum equivalent to 4% of his gross earnings for that week.e) At the en«l of every month, the employer shall forward to the Parity Committee, for and in the name of every one of his employees, the amounts so credited in the month together with the name, address trade ami rate of wages of every one of his employees.Such reports shall reach the Parity Committee within the first 15 days of the month following the month which they cover. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 19(4 OC' année, No 2ô f) Les feuillet de rapport sennit fournies jwr le Comité paritaire.g) Le Comité paritaire déposera les sommes ainsi perçues dans un compte séparé et en accusera réception à l'employeur et aux salariés sur reÇUI spéciaux à ces tins.Il assignera deux de ses membres (un représentant patronal et un représentant ouvrier) à la surveillance de l'administration de ce fonds.h) Le Comité paritaire défrayera le coût de l'administration des argents perçues pour congé spéciaux.X.Prime d'équipe: a) Lorsque le travail nécessite la formation de plusieurs équipes, les travailleurs appelés à exécuter du travail, soit sur l'équipe de 4 heures p.m.à minuit ou de minuit à S heures a.m.recevront une prime de 80.10 cents l'heure en plus du salaire effectivement payé.b) Prime du chef d'équipe: Le travailleur appelé à diriger une équipe de six (8) employés en plus.recevra une prime additionnelle de quinze (0.15) cents l'heure.XI.Période d'attente: Tout salarié se rapportant au travail à l'heure conventionnelle et qui n'a pas été avisé à l'avance que ses services ne seraient pas requis, a droit à une rémunération équivalente à trois (3) heures de travail.L'employeur peut exiger «pie ce salarié demeure à sa disposition pendant les trois (3) heures d'attente.XII.Accidents: Lorsqu'un salarié se blesse en devoir, il est rémunéré pour la journée entière de l'accident pourvu «pie la blessure nécessite un arrêt «le travail suivant l'avis du médecin.XIII.Fonds de sécurité sociale: Un comité d'étude sera constitué par les parties signataires dans le but «le faire l'étude préliminaire sur la rentabilité d'un système «le sécurité sociale semblable à ceux déjà en vigueur à Montréal et à Québec.Sur le rapport «le ce comité qui devra être donné avant la fin du «lécret.les parties aviseront.XIV.Bien être en hygiène: Les employeurs doivent aménager un endroit convenable permettant aux ouvriers de prendre leurs repas si la situation l'exige.Ils doivent également aménager une chambre «le toilette et fournir les accessoires nécessaires tels que savon, serviettes, etc.XV.Période et détails de la paye: a) Le salaire sera payable en entier en monnaie légale du Canada ou en chèque tous les jeudis ou vendre«lis.Si le vendredi est un jour chômé la paye aura lieu le jour précédent.b) Les détails suivants devront apparaître sur ou «lans l'enveloppe de paye: Le nom de l'employeur.Le nom et prénom «lu salarié, Le nom «le sa t fiche, La «late et la péritxle «le paye.1a> nombre d'heures de travail.Le taux à l'heure, Le total du salaire, Les déductions faites en détail.Le montant net «le la paye.XVI.Véhicule: Tout employeur exigeant qu'un employé mette sa voiture à son service devra en défrayer le coût à raison de $0.10 cents du mille.XVII.Casques de sécurité et outils: Le casque de sécurité exigé par la Loi de même que des outils motorisés et les pinceaux seront aux frais de l'employeur.XVIII.Période de repos: Tous les employés auront droit à une période «le repos de dix (10) minutes l'avant midi et une autre période de repos de dix (10) minutes l'après-midi./) Report forms shall be supplied by the Parity Committee.g) The Parity Committee shall deposit such sums in a separate account and shall acknowledge receipt thereof to the employer and employees upon special receipts.It shall assign two of its members (one employers' ami one employees' representatives) to the supervising of the aumi- nistration of such fund.//) The Parity Committee pay the cost of administration of moneys collected for special holidays.X.Shift premium: a) When the work requires the setting up «>f more than one shift, the workers called to work on the 4:00 p.m.to midnight or midnight t«> S:00 a.m.shift shall be paid a premium «»f SO.10 per hour in excess of the wages actually paid.6) Shift leader premium: Workers called to lead a shift of six (6) employees or more shall be paid an additional premium of fifteen (0.15) cents per hour.XL Waiting time: Every employee who goes to work at the usual time and has not been notified in advance that his services wouhl not be required is entitled to a remuneration equivalent to three (3) horns «»f work.The employer may require that such employee remains at his disposal f«>r three (3) hours.XII.Accident: When an employee is injured while «>n duty, he shall be paid for the entire day of the accident when the injury, according to the «loctor, justifies stoppage of work on the part of the employee.XIII.Social security fund: A study committee shall be formed by the contracting parties for the purpose of making a preliminary study as to the practicability «»f a Social Security System similar to those alrea«ly in force in Montreal and Quebec.I pou receipt of the report of such committee, which shall be remitted before the expiration of the decree, the parties shall decide what action shall be taken.XIV.Welfare and hygiene: Employers shall pro-vide for a convenient place where employees, if conditions BO require, may take their meals They shall also put a toilet room at the disposal of the employees with the necessary accessories, such as soap, towels, etc.XV.Period and particulars of the pay: a) Wages shall be paid entirely, in Canadian currency every Thursday or Friday.When Friday is a holiday, the pay shall be made the day before.b) The following particulars shall be mentioned on or in the pay envelope: Name of the employer.Name in full of the employee, \u2022 Name of his occupation.Date and peritxl covered by the pay.Number of hours worked.Hourly rate, Total pay.Deductions made, in detail, Net amount of the pay.XVI.Vehicle: Every employer requiring the services of an employee's car shall pay that employee $0.10 per mile.XVII.Safety helmets and tools: The safety helmet required by law and power tools and paint brushes shall he supplied at the expense of the employer.XVIII.Best period: All employees are entitled to a rest period of ten (10) minutes in the forenoon and to another rest period of ten (10) minutes in the afternoon. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 2004, Pol.\\%\\ No, 25 XIX.Apprentissage: Les taux de salaire XIX.Apprenticeship: The hourly rates of horaires des apprentis sont les suivants pour wages of apprentices shall he as follows : chacun des métiers ci-après mentionnés: Taux horaires Hourly rates ^_ / mars 1 act.J janv.March October Jan.Métiers Trades: /.MCô I.i960 1.i960 n) Briquctcur, plâtrier et maçon Bricklayer, plasterer, mason: Première année - First year.$1.40 $1.02 $1.72 $1.82 Deuxième année\u2022 -Second year.1.61 1.80 1.90 2.00 Troisième année - Third year.1.83 2.01 2.11 2.21 Dans ces métiers, aucun employeur ne peut employer plus d'un (1) apprenti par trois (3) compagnons ou fraction de trois (3) \u2014 In these trades, no employer may have more than one (1) apprentice to each three (3) journeymen or fraction thereof.b) Charpentier-menuisier et poseur de portes et fenêtres métalliques - ( 'arpenter-joiner and metal door and window erector: Première année First year.1.35 1.51 101 1.71 Deuxième année Second year.1.50 1.67 1.77 1.87 Troisième année Thin! year.1.67 1 85 1.95 2.05 Dans ces metiers, aucun employeur ne peut employer plus d'un ( 1 ) apprenti par trois (,3) compagnons ou fraction de trois (3) \u2014 In these trades, no employer may have more than one (1) apprentice to each three (3) journeymen or fraction thereof.r) Mécanicien (Millwright), machiniste, forgeron, poseur de marbre, terrazzo, tuile, vitrolite, mosaïque, finisseur de ciment, jointoyeur, poseur de blocs de ciment, peintre fer structural \u2014 Millwright, machinist, blacksmith, marble, terra/./.o, tile, vitrolite and mosaic layer, cement finisher, joint pointer, cement blocks layer, structural steel painter: Première année \u2014 First year.1.35 1.51 1.61 1.71 I )eux ième année \u2014 Second year.1.46 1.62 1.72 1.82 'Troisième année - Third year.1.61 1.80 1.90 2.00 Dans ces métiers, aucun employeur ne peut employer plus d'un (1) apprenti par trois (3) compagnons ou fraction de trois (3) \u2014 In these trades, no employer may have more than one (1) apprentice to each three (3) journeymen or fraction thereof.d) Électricien \u2014 Electrician: Première année \u2014 First year.1.41 1.34 1.44 1.55 I deuxième année \u2014 Second year.1.25 1.45 1.55 1.65 Troisième année \u2014 'Third year.1.35 1.66 1.66 1.70 Quatrième année \u2014 Fourth year.1.50 1.72 1.82 1.92 II n'y a qu'un ( 1 ) apprenti pour chaque compagnon électricien \u2014 There shall be but one (1) apprentice for an electrician journeyman.e) Peintre, vitrier, poseur de papier-teint blanchisseur à la chaux \u2014 Painter, glazier, paper hanger, whitewasher: Première année \u2014 First year.1.14 1.29 1.39 1.49 Deuxième année \u2014 Second year.1.25 1.40 1.50 1.60 Troisième année \u2014 Third year.1.50 1.67 1.77 1.87 Dans ces métiers, aucun employeur ne peut employer plus d'un (1) apprenti par trois (3) compagnons ou fraction de trois (3) \u2014 In these trades, no employer may have more than one (1) apprentice to each three (3) journeymen or fraction thereof./) Aucun employeur ne peut employer d'ap- f) Xo employer may have an apprentice when prenti s'il n'a pas de compagnon du même métier he has no journeyman of the same trade in his à son emploi.employ.g) Les personnes qui ont fréquenté une école g) Apprentices who attended a school governed régie par la Loi de l'enseignement spécialisé by the Specialized Schools Act shall be given a doivent recevoir un crédit proportionné à la credit in proportion to the duration of their durée de leurs études et aux résultats de leurs studies and to the result of their examinations, exumens.Ii) Carnets d'apprentissage: Tout apprenti doit h) Apprenticeship booklet: Every apprentice, s'inscrire au Bureau d'Examinateurs formé par la-fore beginning his apprenticeship, shall register le Comité Paritaire chargé de l'application du with the Board of Examiners formed by the décret avant de commencer son apprentissage.Parity Committee entrusted with the administration of the decree.i) Le Bureau d'Exuminateurs tient un registre i) The Board of Examiners shall keep a ¦'aliquant les noms, prénoms, âge et adresse de register giving the name in full and address of 1 apprenti, la date de l'admission à T apprentis- the apprentice, the date of his admission to 3372 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 1964, 90' année.S'a Sè sage, le métier exercé et tous renseignement.s jugés nécessaires par le Comité paritaire qui l'a formé.j) (Le Bureau d'Kxaminateurs émet à l'apprenti un carnet «l'apprentissage dans lequel est inscrit par chaque employeur la période «le travail de l'apprenti sous la signature «le cet employeur ou «le son représentant autorisé.k) La «hure «le l'apprentissage est de trois (3) années pour tous les métiers sauf celui «l'électricien «pii est réglementé par le chapitre 172 «les Statuts refondus de Québec, 11)41.Chaque année d'apprentissage «le l'apprenti ou «lu compagnon junior doit comprendre deux mille (2,000) heures «letravail./) A l'expiration de la période d'apprentissage, l'apprenti peut se présenter «levant le Bureau «les Examinateurs pour y subir son examen pour l'obtention de son certificat de compagnon et doit, s'il le fait, remettre son carnet.Kn cas d'insuccès à cet examen, le Bureau d'Kxaminateurs doit remettre au candidal son carnet d'apprentissage ppur une période déterminée.m) Tout apprenti «loit aviser le Bureau d'Kxaminateurs «les nom et adresse «le son employeur cha«pie fois et aussitôt Qu'il change «l'employeur.n) Tout apprenti ou compagnon junior qui a obtenu un changement dans sa qualification au Bureau «l'Kxaminateurs doit en aviser son employeur.XX.Disposition générales: a) l'aie ment du salaire: Les employeurs doivent payer leurs salariés chaque semaine sauf «lans les territoires non Organist's manquant de facilités bancaires où ils peuvent faire leur paie ai tous les quin/c (15) jours.b) L'employeur ne peut «lé«luire du salaire du salarié plus «le $3.00 par semaine et par chambre, s'il loge le salarié et ne peut déduire plus «le $0.25 par repas pour sa pension.c) L'employeur «loit indiquer sur le chèque ou sur l'enveloppe «le paie «le chacun «le SCS salariés les déductions suivantes: assurance-chômage, impôt surle revenu, cotisation «lue au Comité paritaire et contribution syndicale s'il y a lieu en ce dernier cas.XXI.Poseurs de tuile d'asphalte, tuile de caoutchouc, tuiie de plastique, poseurs de prélart.polisseurs de planchers, de tapis et poseurs de stores vénitiens et draperies arec agencements: a) Salaires: Les employés exécutant des travaux non compris dans leur métier ne subiront pas de rabais de salaire.De plus, le temps de déplacement fait pendant la durée du travail «loit être payé par l'employeur, exception faite pour le retour du travail à l'heure des repas.6) Apprentis: L'apprentissage comporte une durée de deux (2) ans et les salaires doivent être les suivants : apprenticeship, the t rade plied and all particular* which the Parity Committee deems necessary.j) the Board of Kxaminers shall issue, in favour of the apprentice, an apprenticeship booklet in which every employer shall inscribe the period of work of the apprentice under bin signature or that of am authorized represent at i\\> k) The period of apprenticeship shall be three (3) years for all trades with the exception of the electrical trade which is regulated by the provisions of chapter 172.R.S.Q., 1941.Every year «>f apprenticeship s/orked by the apprentice or junior journeyman shall consist of two thousand (2.000) hours of work /) At the expiration of his period of apprentie* ship, the apprentice may give his booklet bank to the Board «>f Kxaminers ami sit for his exami nation in order to obtain the journeyman- certificate.In the event of failure, the candidate shall be given back his booklet for such a period as will be determined by the Board.m) Every apprentice shall notify the Board «)f Kxaminers of the name ami address of every one «>f his employers.//) Kvery apprentie*' or junior jourm-ymai who has obtained a change in his qualification before the Board of Kxaminers shall notify his employer to that effect.XX.General provisions: a) Payment Of icinji \u2022 The employers shall pay their employees sverj week except in unorganised territories, without bank facilities, where such payment may be «loue every fifteen (15) «lays.b) The employer shall not deduct more than $3.00 per week, per room from the employee's wages and not more than $0.25 per meal for board.c) Kmployers shall mention on the cheque or on the pay envelope of envery employee the following deductions: unemployment insurance income tax.Parity Committee's assessments and union dues if any.XXI.Asphalt tile, rubber tiie.plastic tile, carpet and linoleum layers, floor polishers, layer, of carpets, venitiun blind and curtain {with fixtures hangers: a) R 'ages: Taux horaires - Hourly rates \t/ mars\t/ oct.\t/ jam \tMarch\tOctober\tJan \t1, I960\t1.1905\t1.I960 $1.92\t$2.10\t$2.20\t$2.30 1.92\t2.10\t2.20\t2.30 1.92\t2.10\t2.20\t2.311 1.92\t2.10\t2.20\t2.30 1.92\t2.10\t2.20\t2.30 1.92\t2.10\t2.20\t2.30 1.92\t2.10\t2.20\t2.30 Employees doing work not comprised in the operations of their trade shall continue to receive the same wages.Also, travelling time, when occurring during working hours, shall be paid by the employer, excepting the return from work at meal time.6) Apprentices: Apprenticeship will consist of a period of two (2) years and wages shall he as follows: Poseur de tuile d'asphalte \u2014 Asphalt tile layer.Poseur «le tuile de caoutchouc \u2014 Rubber tile layer.Poseur de tuile plastique \u2014 Plastic tile layer.Poseur «le prélart \u2014 Linoleum layer.Polisseur de planchers - Floor polisher.Poseur «le tapis \u2014 Carpet layer.Poseur de stores vénitiens et draperies avec agencements \u2014 Venetian blind and curtain (with fixtures) hanger.1ère année \u2014 1st year.2ème année \u2014 2nd year $1.20 $1.35 $1.45 $1.65 1.56 1.73 1.83 1.93 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20.1964, Vol.96, So.2» 3373 1/6 nombre d'apprentis ne doit pus dépasser un (I ) par compagnon.\\1.Durée du décret: Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 30 novembre 1000.Il se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite, à inoins «pie l'une «les parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit pas être «le plus de soixante (00) ni «le moins «le .le trente (30) jour-, avant le premier mars «le l'année I9«>4 ou «le toute année subséquente.I n tel avis doit également être adressé au ministre «lu Travail.I.a pu!-at ion du présent avis uc rend pas obligatoires les dispositions (pli y sont contenues.Seul un urrêlé en conseil peut rendre obligatoires «.s dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en c«)iiseil ne peut entrer en vigueur avant la «late de sa publication «laus la Guz-tte officielle de Québec Durant les trente jours à compter «le la «late de publication «le cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail rcee- \\ ra les objections, en double copie si possible, que les intéressés pourront f its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty f this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections, in duplicate, if possible, which the interested parties may wish to set forth.(¦kkakd Ti«i:\\i»i.av.De put if Minister of Labour.Department of Labour.Québec, -lune 20.1904.7007-o Notice of amendment Sheet Metal Products Fabricating Industry \u2014 Island of Montreal The Honourable Carrier Fortin, the Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties t«> the collective labour agreement relating to the sheet metal products fabricating industry in the Island of Montreal and a radius of 25 miles from its limits, rendered obligatory by the decree number 827 of August 14.195S and amendments, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the said decree; 1.The name «>f the contracting party of the first part will be replace»! by the following: ««Montréal Construction Association (Sheet Metal Fabricating Section) ».2.Paragraph « /) » of article I will he replace»! by the following: \" p) Miscellaneous: Workmen regularly employed as shippers, warehousemen, stock keepers, helpers to power shear or power brake operators, packers ami craters shall be paid $0.05 per hour in excess of the helpers' minimum rate.The employee in charge of those departments shall be paid $0.15 per hour in excess of the helper's minimum rate.However workmen temporarily employed as above shall retain their regular rates of pay\".3.Paragraph \"//' of article III will be replaced by the following: \"«*») The «lecree shall not apply to the manufacturing «ir fabricating of electric cooking stoves, the construction of boats over 25 feet long, aircraft or the manufacture and fabrication of -the following products: cans and utensils; domestic electric refrigerators ami domestic electric humidifiers; electric lamps, electric lighting fixtures ami electric lighting acessories\". 8874 GAZETTE OFFICIELLE DE QVEttEC 40 juin 1964.96* année.So 25 \u20221° L'alinéa suivant sera ajouté au paragraphe « a » de l'article V: « Toutefois, lorsqu'un employé est requis par son employeur dé commencer plue tard que l'heure régulière établie pour l'atelier et lorsqu'il est requis pur son employeur de travailler plus tard que l'heure régulière de cessation «le l'atelier, il a droit au taux pour travail supplémentaire établi plus haut comme s'il avait commencé de travailler à l'heure normale.» 5° Le nouveau paragraphe « C » suivant sera ajouté à l'article Vi «c) Les taux «le salaire et «lemi ou salaire double doivent être calculés sur les taux «le salaires effectiveinent payés, » 13° Le nouvel article XII-A suivant sera ajouté : « XII-A.Sun-pension: Dans les cas de suspension, les salariés doivent en être avisés un jour complet avec telle suspension.» 14° Le nouvel article XHI-A suivant sera ajouté: « XIII A.Un plan de bien-être ne comprenant pas un plan de pension doit être établi au 1er janvier 1965.Les parties formeront un Comité d'étude afin «l'établir les bénéfices «le sécurité sociale auxquels auront droit les salariés assujettis au présent «lécret à compter du 1er janvier 1965.Le Comité d'étude s'efforcera de soumettre son rapport aux parties contractantes assez tôt pour permettre d'appporter les amendements au décret de façon qu'ils entrent en vigueur au 1er janvier 1965.Il est entendu que le coût de tel plan de bien-être sera à la charge des employeurs et sera fixé à un maximum de $0.07 par heure de travail.h) Leading hands shall receive tue ($0.10) cents per hour more than the minimum deter-miued in the «hrn'e for th«*ir classification./) The minimum rates of wages mentioned in the present Article are in force in Zone I.The same rates, less \\()'/(.apply in /.one II.\" f the Village of St-Hilaire, county of Rouville.dated August 1st, 1904 and redeemable serially from August 1, 1965 t«> August 1, 1984 inclusively, with interest at a rate not less than 5%, nor more than 0%, payable semi-annually on February 1st ami August 1st of each year.The rate «)f interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Resolution dated March 12, 1904 \u2014 $110.000 \u2014 Six classroom extension to the Mountain-view Intermetliate School.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from August 1, 1964. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 1964.96' année, No 26 3384 Tableau d'amortissement - $IIO,(KX) 20 ans Année Capital 1er août 1966.x$l 9.000 ler août 1966.x 20.000 1er août 1967.i 21,500 1er août 1968 .2,000 1er août I960.2.0(H) 1er août 1070.2.0(H) 1er août 1071.2.0(H) 1er août 1072 .2,000 1er août 1073 .2,500 1er août 1074.2,500 1er août 1075.2.5(H) 1er août 1070 .3.0(H) 1er août 1077.3.000 1er août 1978 .3,000 1er août 1079.8,500 1er août 1980.3.5(H) 1er août 1081 .3.500 1er août 1988.4.000 1er août 1083.4.(HH) 1er août 1084.4.500 Les « x » indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi de 863,000 accordé par le gouvernement provincial et payable en trois versements do 821,000 chacun, de 1005 à 1907 inclusivement, seront reçus et appliqués au service do cet emprunt.Do plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans ou si courte échéance quinze ans.Cependant les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Montréal.Ix?capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec, de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas racheta-hles par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à \\% «lu montant «le l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des Commissaires d'écoles qui sera tenue 1 undi, b juillet 1904, a 8.30 heures p.m., à l'Ecole élémentaire Mounlainview, 11, rue Hélène.Otterhurn Park, comté «le Rouville.Les commissaires d'écoles se réservent le «Iroit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Hilaire.(Comté «le Rouville), ce 17 juin 1904.Le Secrétaire-trésorier, M.W.(i.HlGGS.300.Richelieu Sud, St-Hilaire, (Rouville).P.Q.Téléphones: 367-6461 ou 367-4849, co«le 514.7030 Syndicats professionnels Syndicat des producteurs d'œufs de consommation du Saguenay Lac-St-Jean (Loi des syndicats professionneh) La constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom-de « Syndicat des producteurs d'œufs Table of redemption $110,000 \u2014 20 year.Year ( 'apital August 1, 1965.x$19,000 August 1, 1900.x 20,000 August 1, 1907.X 21,500 August 1.1908.2.0(H) August 1.1909 .2.000 August 1, 1970 .2,000 August 1.1971.2,000 August 1.1972 .2,000 August 1.1973 .2.500 August 1.1974.2,500 August 1.1075.2,500 August 1.1970 .3.000 August 1.1977 .8,000 August 1.1978.3.0(H) August 1, 1979.3.500 August 1.1980.3,500 August 1, 1981.3,500 August I, 1082.4.0(H) August 1.1083.4.000 August 1.1984.4.500 The \"\\\" Indicate the years during which annual payments of a total amount of $03.01 in.granted by the Provincial Government and payable in three instalments of 821,080 each, from 1965 to 1907 inclusively, will be received an«l applied t«> the service «>f thisloan.Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered for ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall he considered f«»r one «»f the three term-only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal ami accrued interest, if any.by certifie»! cheque payable at par at Montreal.Principal ami interest are payable at all branches, in the Province of Quebec, of the bank mentioned in the loan proce«lure, as well as at the principal office of the said bank in Toronto.The said bonds shall not be redeemable by anticipation.Each tender must be sccompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue ami must specify whether the interest accrued on the bonds to the date «»t their delivery is incluedd or n«)t in the price ol the tender.The tenders will be opened ami considered at a meeting of the school commissioners to he held on Monday.July 0, 1904 at 8:30 o'clock p.m.at Mountainview Elementary School.11.Helen Street, Otterhurn Park, county of Kouville.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest «>r any of the tenders.St-Hilaire.(County of Rouville).June 17.1904.Mr.W.(i.HlGGB, Secretary-Treasurer.360, Richelieu South, St-Hilaire, (Rouville).P.Q.Telephone: 367-0161 or 307-4249.code 514.7030-O Professional Syndicates Syndicat des producteurs d'œufs de consommation du Saguenay Lac-St-Jean (Professional Syndicates Act) The incorporation of a professional syndicate, under the name of \"Syndicat des producteurs QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 90, I9t'4, Vol 90, .Vo.25 3385 tie consommation «lu Sagticnay Lac-St-Jean », a été autorisée par le secrétaire «le la province, le 23 mars I0d4.Le siège locicJ dudit syndicat professionnel esl situé à 533, rue Racine, est, ('liieoutimi, «listrict judiciaire de ('hicoutiini.Québec, le 1er avril 1964.Le Sou*.secrétaire de la prorince, 6976-e Raymond Douvillb.d'oeufs de consommation du Saguenay Lac-St- \u2022lean\", has been authorised by the Provincial Secretary on Mar«h 23.1964.The lieatl oflice of the said professional symli-cate is situated at 533 Racine St.Bast, Chieou-tiiui.judicial district of ('hicoutiiui.Quebec.April 1.1964.Raymond DoUVILUfi, 6976 Assistant Secretari/ of the Province.\\*->ocintion*des instituteurs et institutrices , cutholiqiies du comté de Boiiaventtirc (Loi des syndicats professionnels) Wis est donne «pie le secrétaire «le la province a le 14 mai 1964, autorisé le changement «!f \"Le Syndicat professionnel des Instituteurs catholiques «le Hull\", of which incorporation has been authorized on April 21, 1952, ami which head office is situated at Hull, to that of ('\"Association régionale des instituteurs catholiques de l'Outaouais\", and such, pursuant to the provisions of Professional Syndicates Act.Revise*! Statutes of Quebec, 1941.chapter 162.Quebec, dune 1.1964.Raymond Douvillk.7026 Assistant Secretary of the Province. .\u2022«su GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉHEC.20 juin 1964, 9C année.No $6 Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC, est par le present donné que les TERRES et HÉRITAGES soue-mentionnee ont «''té saisis «'t seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus has.CHICOUTI M I Fieri Fartas District de ( 'hieoutimi Cour Supérieure, (TA BANQUE PROVIX-No 34,704.< CÎALE DU CANADA, ' corps politique et incorporé, avant son siège social «-t sa principale place d affaires «lans les cité et district de Montr«:al.demandeur, m MADAME MARIE ANGE MALTAIS, épouse judiciairement séparée de corps de Gérard Budon, «le Jonquière, «listrict de ( 'hicoutiini, défenderesse.« lin lopin de terre faisant partie «les lots numéros viugt-scpt-R-t'cnt-vingt-ipintrc «-t vingt-sept-Bcent-vingt-cinq (P.27-B 124 et 27-B 125) «lans le rang trois au cadastra ofliciel «lu canton de Jonquière, pouvant être plus particulièrement décrit : a) Toute cette partie «lu lot numéro vingt\" sept-B-cent-vingt-cinq (P.27-B-125) mesurant quinze pieds de largeur «le l*est à l'ouest sur toute la profondeur «lu lot et bornée au nord par la rue Ste-Cécile, au sud par le No 27-B-125-A.à l'est par le terrain ci-après décrit au paragraphe « b ».à l'ouest par le résidu dudil lut dont il forme partie, propriété de René Villeneuve, ou représentants: b) Toute cette partie du lot numéro vingt-sept-B-cent-vingt-quatre (P.27-B-124) mesurant trente pieds «le largeur de l'ouest à l'est sur toute la profondeur «lu lot.bornée au nord par la rue Ste-Cécile, à l'est par le résidu «lu lot dont il forme partie, propriété des « Immeuhlcs (iagnon Limitée ».au sut! par le lot No 27-B-124-A, à l'ouest par le terrain ci-dessus décrit au paragraphe « a ».Avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu à la porte «le l'église paroissiale «le St-Laurent.cité «le Jonquière, le VINGT-TROISIÈME jour du mois de JUILLET 1904.à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau «lu Shérif, Rknk Dklisle.Chicoutimi, le 12 juin 1964.7031-25-2-o IBERVILLE Canada \u2014 Province de Québec District d'Iberville Cour Supérieure, f JACQUES CARTIER, avo-No 13,153.\\J cat, domicilié en les villes ' et district d'Iberville, demandeur ai GRÉGOIRE ET CIE LTÉE, corporation commerciale ayant sa place d'affaire à Henry-ville, dans le district d'Iberville, défenderesse.s 1.Partie des lots numéros trois cent quatre et trois cent cinq du cadastre officiel de la paroisse de St-Georges d'Henryville, de forme irrégulière, partant d'un point A, situé à l'intersection nord- Sheriffs' Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times ami places mentioned below.CHICOUTIMI Fieri Farias District of Chicoutimi Superior Court, i npil E PRONVICIAL No.34.704.j * BANK OF CANADA 'body politic and corporate, having ils head office and principal place of business in the city ami «listrict of Montreal, plaintiff, m MRS.MARIE ANGE MALTAIS, wife judicially separate as to bed ami board of Gérard Hudon.«»f Jonquière, «listrict of Chicoutimi.defendant.\"A strip of laud forming part of lots numbers twenty-seven-B-one hundred ami twenty-four and twenty-seven-B-one hundred and twenty-five (Pt 27*-B-124 ami 27-B-125) in range three on the officiai cadaster of the township of Jonquière, which, in detail, may he described as: a) All that part of t«>t number twenty-scu i B-one hundred and twenty-five (Pt 27-B-I2.V measuring fifteen feet in width from east t«» wrest along the entire depth of the lot .and bounded on the north by Ste-Cécile St.on the south, by No.27-B-125-A.on the east, by the lot of land hereinafter mentioned in paragraph \"b\", on the west, by the residue of the sai«l lot of which it forms part, property «»f René Villeneuv»-.or representatives: 6Ï All that part «>f l«>t number twenty-seven B-one hundred ami twenty-four (Pt 27-B-124) measuring thirty feet in width from west to east along the entire «lepth of the lot.bounded on the north by Ste-Cécile Street, on the east, by the residue of.the lot of which it forms part, properly of \"Immeubles Gagnon Limitée\", on the south, by lot No.27-B -124-A.on the west by the lot above described in paragraph \"a\".With all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.\" To be solil at the parochial church door of St-Laurent, city «»f Jonquière, on the TWENTY THIRD «lay of the month of JULY.19G4, at THREE o'clock in the afternoon.Ri:n£ Dki.islk.Sheriffs Office.Sheriff.(hieoutimi, June 12.1964.7031-25-2 IBERVILLE Canada \u2014 Province of Quebec District of Iberville Superior Court, f JACQUES CARTIER, ad-No.13,153.\\ J vocate, residing in the ' town and district of Iberville, plaintiff, r* GREGOIRE ET CIE LTÉE, commercial corporation, having its head office in Henryville, in the district of Iberville, defendant.\"1.Part of lobs numbers three hundred and four and three hundred and five in the official cadaster of the parish of St-Georges d'Henryville, irregular in shape, starting at point A situated at QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, .lune 20, W4.Vol.96, No.96 3387 esl 001 rut's St-.hisepb et St-.leun-Hapti.ste, «le là, allant vers l'est.longOMll ladite rue St-Jean-baptiste, une distance «le trois cent soixante-dix |iicds et un cimpiièmc dé pied, en passant par un point H, jusque un point (I, à l'intersection «le ladite rue St-.lcan-Baptistc et et un ruisseau, joignant le l«d \\«» 308 dudit ea«lastre, «le là.allant vers le nord-ouest et ensuite vers le nonl, tout en longrth-west, and finally towards the north, all lying along the sai«l brook as far as point F, then as far as point E; thence, going towards the north-west, still lying along the said brook, as ar as point D situated at the intersection «jf the «-ast line «»f the part of lot No.305-A in the said cadaster belonging to Mr.Albert Grégoire or representatives, ami the said brooks thence, going towards the south, lying along the said east fine, as far as point L, a «listance of eighty-eight feet; thence, going towards the «'ast, lying along the north line of the property f General Veneer or representative; as far as point M, a «listance of eighty-five feets thence, going towards the south, along the east line «>f the said property as far as point N, a distance of eighty-five feet; thence, going towards the west, lying along the south line of the said property, as well as the south lino of the property beloning to Mr.Albert Grégoire, passing hy point O, in a straight line as far as St-Joseph St., a «listance of two hundred and oie ami one-tenth feet to join the starting point A; save to be withdrawn, however, from the said immoveable, is the part triangular in shape sold to (îeneral Veneer or representatives.2.Lot number three hundred ami seventy-six in the said cadaster; save and to be withdrawn are the parts sold to Messrs Albert (îrégoire, Orphs Coupai, an«l Emile Desgroseillers, by deeds drawn up before Me Rodolphe Fournier ami Yves Fortin, notaries.3.Part of lot number three hundred and eighty-five in the said catlaster, irregular in shape, starting at point J, at the intersection of the lines «>f lots Nos.384 an«l 385 in the said cadaster; thence, lying along the west line of the former Quebec-Montreal-S«>uthern Railway, going towards the south, a «listance of eight undred and ninety and one-half feet, as far as point T; thence, going towards the south-east, as far as point S, a distance of one hundred and six and one-tenth feet; thence, going towards the southwest, lying along the east line of the said railway as far as point R, a distance «>f six hundred and ninety-seven feet; thence, going towards the south-east, in a straight line as far as point Q, a distance of two hundred and thirty-nine and two-tenths feet; thence, going towards the north, lying along lot No.387a in the said cadaster, as far as point P, a distance of two hundred and fifty-eight and one-third feet; thence, going towards the east, lying along the line of lot No.375 in the said cadaster, as far as point H, a distance of six hundred and sixty-seven ami one-half feet; thence, going towards the north-west, lying along the west line of said lot 376, a distance of sixteen hundred and fifty-three and one-third feet, as far as the starting point.With the buildings thereon erected.\" To he sold at the church door of Saint-tïeorges d'Hcnrvville, on the ELEVENTH day of the month \"of JULY, 1964, at TEN o'clock in the forenoon.R.Pur d'homme, Sheriff's Office.Sheriff.Saint John, May 25, 1964 .6796-22-2 3388 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 20 juin 1964, 96' année.So 25 KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris ( anada \u2014 Province «le Québec District de Kamouraska Cour Supérieure, / T A CORPORATION DE Kamouraska.) FI N A N ( ' E ST A N 1) -No 22-566.i A R D - STANDARD FI -I NANCE CORPORATION, corporati«)n légalement COuStitUée avec siège social à S05 d'Aiguillon en les cité et district de Quéhec, «lemaudere.sse, rs LEO SOUCY, «lomi-cilié à St-IIonoré, comté «le Témiscouata, «l«;fen-«leur.« L'n emplacement contenant 1)5 pieds de largeur, le long «lu chemin puhlic par 05 pieds «le profondeur, plus ou moins, horné en front, au nord, à la route nationale, au sud au terrain «le Irene Beaulieu, à l'ouest et à l'est au terrain de la heurrerie de la paroisse «le St-Honoré.Lequel emplacement fait partie des lots 35-B et 36-A, rang C, canton Armand, avec hâtisses «lessus construites.» Pour être vendue à la porte «le l'église «le St-Honoré, comté «le Témiec ouata, le SEPTIÈME (7e) jour de JUILLET 1064, à DEUX (2) heures de l'après-midi.Bureau «lu Shérif, Le Shérif.Rivière-f Quebec, plaintiff, m LEO SOUCY, domiciled at St-Honoré, county of Témiscouata defendant.\"An emplacement containing 95 feet in width, along the public Hoad, by 66 feet iu depth, more or less, bounded iu front to north by the highway, to south by Irene Beaulieu land, to west and east by the butter-dairy «>f St-Hoiiorc parish.The said emplacement forming part ol lots 35-B ami 36-A, range C, township of Armand, with buildings thereon erected.\" To he sold at the church «loor of St-Honor.county of Témiscouata, on the SEVENTH (7th) «lay of JULY, 1964.at TWO (2) o'clock jn the afternoon.Sheriff's Oflice.MaUUJOB Moriv.Rivière-du-Loup, Sheriff.May 26, 1964.6788-22 I (First insertion: May 30, 1964J QUEBEC Fieri Facias Quebec, to wit: 1 p J.CHARTIER INC., Superior Court, ) body politic and corpo- No.129-944.\\ rate, having a place of business V in the city and «listrict of Quebec, versus J.NOËL SIMARD, of the city and district of Quebec, P.Q.\"A lot of land bearing number 2756, hounded on the northwest by lot No.2757, on the southeast by No.2755, on the northeast by Ste-Angèle St., and on the southwest by Nos.2763 and 2764, measuring fifty-eight feet ami seven inclus (58'7\") on the line which divides it from No.2757, fifty-four feet ami ten inches (54' 10\") on the line which «livides it from No.2755, forty four feet ami seven inches (44'7\") on Ste-Angèle St., and forty-four feet (44 ) on the line which divides it from Nos.2763 and 2764; having an area of two thousand five hundred and six feet, English measure (2506'), equal to two thousand two hundred ami six feet (2206'), French measure, circumstances ami dependencies.To be sold in rav office, in the Quebec Court House, on the SECOND «lay of JULY next, at TEN o'clock in the forenoon.Me Antoink Bouroet, q.c, Sheriff.Sheriff's Office, Quebec, May 26, 1964.6797-22-2 (First insertion: May 30, 1964) [Second insertion: June 20, 1964] Fieri Facias Quebec, to wit: ff^RANE CANADA LI M C.S.ITED, body legally ine No.129-991.\\ orporated, carrying on busi-\\ ness at 460 St-Roch, city and district of Quebec, versus RAYMOND VEK REAULT, 321 Durocher St., city and district of Quebec, and ALBERT SOULARD, 323 Dur.) QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 20, 10C,Jt, Vol.9(1, No.2» 3389 cité et district de Québec et J.C.FICHER, rogistrateur, 20 Chauveau, cité et district de
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.