Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 décembre 1966, samedi 17 (no 50)
[" 98» année vol.98 N° 50 6207 Suritf officielle ie Québec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE Québec, Mmedi 17 décembre 1966 Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur «le l«i reine.Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte otli versions).Subsequent insertions: io cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists «>f names, figures, « \u2022 t « -.» at double rate.Translation: Si per 100 words.Single copies: 40 cents each.Slips: 81.50 per «lozen.Subscriptions: 810 per year from January.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notice, have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third to the manner f insertion, anil the letter \"o\" signifies that tli deal in wood) under the name of \"A.C.1).inc.\", with a total capital stock of 840.000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head of lice of the company is at Amos, judicial district of Abitibi.Raymond Doi; ville.Assistant Secretary of the Province.1700Ô 4804-66 A.& J.Restaurants (Dorval) Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 4th day of November, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: John Strotman, restaurateur.Carol Strotman, housewife, wife separate as t«» property of the said John Strotman, both \"f 4439 Kingston, Pierrefonds, an«l Adrien Strot-man, restaurateur, 725 Tait Street, St-Laurent, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"A.& J.Restaurants (Dorval) QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, December 17, 1966, Vol.US, A'».50 8209 avec un capital total de s10,000, divisé en 4,000 ,n lions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 330, chemin Dorval, Dorval, district judiciaire «le Montreal.I.e Sou.s-.iecrétaire Je la province, Raymond Dou ville.17(105 4000-6») Acadian Industries inc.\\\\i> est donné qu'en vertu «le la première partie de la l which the value «>f the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation is at Wont-real, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Sccretan/ of the Province.17605 4133-6fi Geneva Baubien Enterprises Inc.Notice is given that under Part I «»f tla-Companies Act, letters patent, bearing «late the 20th day of October, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Isidor Raymond Hart, 4008 Ponsard Avenue, Montreal, Avrom Podberc, 0525 Merton Road, Côte-St-Luc, and Leonard II.Wisse, 4270 Western Avenue, Westmount, all three notaries, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Geneva Baubien Enterprises Inc.\", with a total capital stock ol $40,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $1 each, 2,000 class A preferred shares of the par value of $1 each and 37,00'» QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 17, 1968, V4.US, So.:,o 0301 unir de $1 ohftOUne et en 37,000 actions privilégiées catégorie « H » d'une valeur au pair de $1 i liacune.I.e liage lOOlal de la compagnie est 4950, i hciiiin de la Reine Marie, suite 425, Montreal, district judiciaire «le Montréal.Le Soils-.secretaire de la provint! .Raymond Douville.17005 4364-00 class H preferred shares of the par value ièg«' social «le la compagnie est à Montreal, district judiciaire agnic est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.1700Ô 408646 Robert Bishara Text des Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accorde des lettres patentes, en date du 4e jour de novembre 1966, constituant en corporation: Robert Bishara.marchand, Diana Alxmd, ménagère, épouse séparée de biens dudit Robert Bishara, tous deux de 11482, James Morrice, et Maurice Aboud, marchand, 7254, Lajeuness'*, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de textile et de draperies, sous le nom de « Robert Bishara Textiles Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 3423 ouest, Notre-Dame, Montréal, ^district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.17005 ft.4528-00 The head ollicc of the company is at JIJ Cartier Boulevard, Laval, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Provinii.1760S 4477-66 Better Living Punishing Corporal ion NotiOB is given that under Part 1 of tin-Companies Act.letters patent, bearing date tile 7th day of October, 19t>0.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul (î.I'nterberg, 1700 Me.Gregor, Bernard Sivak.7910 Côte-St-Luc.both advocates, and Patricia Perry, scf November.1900.have been issued by the Lieutenant-Governor «»f the Province.incorporating: A«lrien-R.Pa«|Ucttc, advocate, 212 Bloomfield.Outremont.Gisèle Tourville.1575 Summerhill.Apt.415.and Micheline Pilotte.0727 Charlevoix, the two latter secretaries, spinsters of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Bruno transport inc.\".with a total capital stock of 840.000.divided into 2,000 common shares of 810 each and 2.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dor ville.Assistant Secretary of the Province.17605 4499*66 Buffet St-Qaude inc.Notice is given that under Part 1 «>t the Companies Act.letters patent, hearing date the 31st day «>f October, 1900.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Joselyn Lemaire, contractor, Simone Durand, housewife, wife contractually separate as to property of sai«l .locelyn Lenu-irc.and Michel Lemaire, technician, all three if 120 Fortin.Laval, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, and to cary on the operations of an investment and holding company, umler tile name « f \"Buffet St-Claude inc.\", with a total capital >tf 8304)00, divided into KOO common ihares of 885 each and 400 preferred shares of 825 each.The head office l the company is sit 50 Sala berry, Chateaugusy-Center, judicial «listrict ,,\\ Beaunarnols, Raymond Dot villi.Assistant Secretary of the Province.17605 1102-06 I.r the following purposes: To operate a driving and apprenticeship school for the operators « f motor vehicles, heavy equipment and heavy machinery, under the name «if \"Centre de formation de chauffeurs professionnels inc.- 'Professional Drivers Training Center Inc.\".with a total capital stock of $100.000, divided into 2.000 common shares oration : Fernand Garneau, hôtelier, Dolbeau, Charles-Henri Bouchard, 219.Duberger, Aima, et Jean-Marie Desjardins, Quartier Del isle.St-Coeur-de-Marie, ces deux derniers vendeurs d'automobiles, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, auberges et restaurants, sous le nom de « Le Château Dolbeau limitée ».avec un capital total «le $30,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune Le siège social de la compagnie est à Dolbeau, district judiciaire de Roherval Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvilli.17005-o 3973-00 The amount to which is limited the value i the Immoveable property which the corpora tion may acquire or possess is $30,000.The head office «»f the corporation i* at Si .leau-Yianncy, juilicial «listrict «>f Chicnulimi Raymond Dou villi;.Assistant Secretary of the Proline/.17005 3140-6(1 Centre prol< s-ioimcl St-Jean inc.Notice is givi'ii that umler Part I of the Companies Act, letters patent* bearing date tin?17th day of October, 1006, have been issued by the Lieutenant-Governor «»f the Province, incorporating: Dr.Francis Rémillanl, doctor, Claude Trudeau, lawyer, both of 234 Longuei il, Dr.Jacques Dufresne, and Dr.Jean-Mars Pounder, the latter t\\\\«» doctors f Laval, f«>r the following purposes: To operate a retail store for the sale of men's, ladies' and children's wearing apparel, under the name of \"Dominic's Ltd.\u2014 Chez Dominique ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided int«> 25,000 common shares of a par value of $1 each and 7,500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.17605-o 4443-00 6812 GAZETTE OFF 1C1 ELLE DE QUÉBEC, 17 décembre 2066, US' année, >C 60 Doyon vêtement» ltée Avi-, est donné qu'on vertu do In première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant- gcuverneur de la province n nocordé des lettres patentes, en date du 20c jour d'octoOrc 1900, constituant en corporation: Joseph Laurent Doyon, commerçant.Henriette Marchand, ménagère, épouse séparée «le Liens dudit Joseph-Luurcut Doy«>n, tous «leux «!«' .'1312, «le lu Montagne, et Aurèle Doyon, vendeur.1402, St-Joseph, app.4, tous trois «le Shawinigun, pour les objets suivants: Fair*' affaires comme tailleurs et faire !«\u2022 commerce «le vêtements et tissus «le toutes s«>rtes, sous le nom «le « Doyon vêtements Itéc », svoc un capital total «le 140,000, divisé en 400 actions ordinaires §100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Shawini- gan, district judiciaire «le BûMaurice.Le Smu-êecrétaire de la province, Raymond Doi -ville.1700Ô-o 4356-66 Raoul Kmond «'onstriiction inc.Avis est donné qu'en vertu «!f the company is at Vanier.judicial district «>f Quebec.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the ProvillCt 17605 4280-66 Les Entreprises Chant LU y inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date tile 20th day f the Province, incorporating: Henri Roman Jr.contractor.237 Richelieu Road.Amlré Gagnon.notary.\u2022\"> '2 Raymond Street, both «>f Saint-John, and Rosain Jannelle, contractor, Napierville, for the following purposes: .To carry on business as a real estate and building company, umler the name «»f \"Les Entreprises Chantilly inc.\", with a total capital stock «.f 840.000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office f the company is at 237 Richelieu Road.Saint-John, judicial district »l Iberville.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Provinct 17605 4339-60 Les Entreprises Dorval inc.Notice is given that umler Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of October, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor «.f the Province, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 17, 1966, Vol.US, So.60 cniNiitiiuiit en corporation: Alexander Blcga, 11ni.Upper Bellevue, Westmount, Fernaud Beauregard, 0437, hou levant Pie IX, Montréal, tuUN deUX uvociits, et Nicole ('lenient, secrétaire, lilli inajeure, 5132, rue Rimbaud.St-Léonanl, |K>ur lei objets suivants! Exploiter des magasins, ateliers, boutiques, liAtels, tavernes et restaurants, sous le nom de |.s Knti-eprises Dorval inc.», avec un capital total de 140,000, divisé en 40 actions ordinaires île til00 chacune et eu 860 actions privilégiées de su ii chacune.I.r Mègc social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrftaire de la province, Raymond Douvillk.176064) 4202-66 incorporating: Alexander Biejra, 108 Upper Bellevue, Westmount, Pernand Beauregard, 0437 Pie IX Boulevard, Montreal, both lawyers, uud Nicole ('lenient, .secretary, fille majeure, 5132 Rimbaud Street.St-Léonard.for tué following purposes: To operate stores, shops, hotels, taverns and restaurants, under the name of \"Les Entreprises Dorval inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 40 common shares of $100 each ami into 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Pnnince.17606 4202-60 I.es Entreprises Geneviève Gauthier inc.Les Entreprises Geneviève Gauthier inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 17th day of October, 1066, have been ieiued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Alexander Riega 100 Upper Bellevue.Westmount* Pernand Beauregard.6437 Pie IX Boulevard.Montreal, both lawyers, and Nicole Clément, secretary, fille majeure.5132 Rimbaud.St-Leonard, for the following purposes: Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant- gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en «late «lu 17e jour d'octobre 1066, constituant en corporation : Alexander Biega.uni.Upper Bella vue, Westmount, Pernand Beauregard, 6487, boulevard Pie IX.Montréal, tous deux avocats, «-t Nicole Clément, secrétaire, tille majeure.5132.Rimbaud, St-Lé«»nnr«l.pour les objets suivants: Exploiter «les hotels, tavernes, restaurants.magasins et ateliers, sous le nom «le * Les Entreprises Genevière Gauthier inc.- , avec un capital total «le 840,000) divisé en 40 actions ordinaires \u2022le s|(;(( chacune et en 360 actions privilégiées de 1100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-sccrftaire de la province.Raymond Douvillk.I7605-o 4172-00 Entreprise Plumeau ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-goi vcnicur de la province a accordé «les lettres patentes, en «late du 21e jour d'octobre 1066, constituant en corporation: Y von Pépin, ta vernier, Gilberts Roux, ménagère, épouse séparée il«' biens dudit Yvon Pépin, tous deux «le 41C.Aqueduc, Victoriavillc, et .lean-Man1 Lessanl.gérant île personnel, 2.rue Lessard, L'Ancienne-Lorette, pour les objets suivants: Exercer !«\u2022 commerce d'entretien «le bâtiments commerciaux et autres, sous le nom de « Entre-prise Plumeau ltée », avec un capital total «le 840,000, divisé en 210 actions ordinaires «le 8100 chacune et en 200 jutions privilégiées de $100 chacune.I.c siège social de la compagnie est 919.d'Aiguillon.Québec, district judiciaire «le Québec.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.I7605-o -1341-00 Fairmount Restaurant Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant- gouverneur «le In province a accordé des lettres patentes, en «late «lu 20c jour d'octobre 1960.constituant en corporation: George A.Bcy, 336 ford, Ballantyne, Michael Awada, 11230, Joseph ( asavant, tous deux avocats, et Christel Dodell, secrétaire, célibataire, 7830, Mountain Sights, tous trois «le Montréal, pour les objets suivants: To operate hotels, taverns, restaurants, stores and simps, under the name 0 pn*ferro«l shares of 8100 each, The bead office of the company is at Montreal, judicial «listrict of Mont real.Raymond Dot villk.Assistant Sicretari/ of the Province.17005 4172-66 Entreprise Plumeau ltée Notice is given that under Part I «>f the Companies Act.letters patent.I tearing «late the 21st day of October, 1966.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Yvon Pépin, tavern keeper, Gilberts Roux, housewife, wife separate as to property «if said Yvon Pépin, both scph Casa vaut, both advocates, and Christel Dodell, secretary, spinster, 7830 Mountain Sights, all throe of Montreal, for the following purposes: 0814 (i.iXETIE OFFICIELLE DE QI'ÊIIEC, 17 décembre 1900, 98e année, n° ÔO Kx«t«-«t le t-nmmcrcc f the company is at St-Eugène, county of L'Islet.judicial district ctanakis, ménagère.épouse dudit Harry Kapetanakis, et dûment autorisée par «\u2022«\u2022 dernier aux fini «les présentes, tous \u2022 leux de 4832, avenue «lu Par»-, et (ïeorge Papa- thanakos, gentilhomme, 5157.avenue «lu Pare.tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Entretenir et exploiter «les postes «le diffusion «\u2022t «le réception par ra«li«» «-t T.S.F.aux fins «l«-transmettre ou «le re*-ev«»ir «les messages «le toute Mite par air, T.S.F.ou radio, sous le innn «le ' (JrtM'k Had in Wire Programs Inc., avec un capital total «le 140,000, divise en 1.000 actions ordinaires de 810 chacune «\u2022( .'t.(KM) actions privi- légièes «le 810 chacune.I.e siège social de la compagnie est 4030, avenue «lu Parc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sens iteréiain de la province, Raymond Doivillk.17000 4357-66 Greek Kudio Wire Programs Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing «late the 25th day «>f October, 1900, have bean issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Harry Ka|>ctauakis, executive, Tina Kapetanakis, housewife, wife of the said I I.e Kapttanakis, ami «luly authorized by him for the pur|Mise of these presents, both of 4832 Park,Ave-nue, ami George Panathanakos, gentleman, 6157 Park Avenue, all three «»f Montreal, for the follow iug purposes: To maintain ami operate radio and wirelciu broadcasting and receiving stations f«tr the purposes of transmitting or receiving through the air, wireless or radio messages «)f any kind, under the name of \"Greek Radio Wire Programs Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 ffommon shares of 810 each and 3,000 preferred shares «>f 810 each.The head oflice of the company is at 4630 Par, Avenue.Montreal, judicial district «>f Montreal.Raymond Dor villk.Assistant Secretary of the Province, I7606-o 4357-60 l^cs Habitations Noël inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a aercorde «les lettres patentes, en date «lu 28e jour d'octobre 1900.constituant en corporation: Madeleine Mailloux.secrétaire, fille majeure, 2401.Sheppard.Guy Rousseau, atlministrateur.5274.9e avenue, tous «leux «le Montréal, et Ange-Ainn'-e Hra/cau.c«»mmis-coiuptal)le.400».Merton.St-Lamhcrt.pour les objets suivants: Faire affaires conune compagnie d'immeuble et «le construction, sous le nom «le « Les Habitations Noël inc.avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 écrions ordinaires «le $10 chacune «'t en 300 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie est à La Sarre» district judiciaire d'Abitibi.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Dou ville.I7006-o 4421-00 (.«raid Henry inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour d'octobre 1900.constituant en corporation : Gérald Henry, entrepreneur, rue Wood, St-Chrysostôme, Hélène Miehaud.807.rue Dulutli est, et Marcelle tournoyer, 5170, lie avenue, ces deux dernières secrétaires, filial majeures, «le Montréal, pour les objets suivants: Kxcrcer le commerce d'une compagnie «le transport, d'entreprise et de sous-entreprise, de construction et de développement général, y compris le commerce de garagistes, ainsi que les affaires d'une compagnie de portefeuille, de placement et de gestion, sous le nom de « Gérald Henri inc.», avec un capital total de $100,000.divisé en 5.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 5,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Les Habitations Noël inc.Notice is given tliat under Part I «>f the Companies Act, letters patent, bearing «late the 28th day of October, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor «»f the Province, incorporating: Madeleine Mailloux.secretary, fille majeure, 2401 Sheppanl.Guy Rousseau, administrator, 5274.9th Ave., Loth of Montreal, and Ange-Année Braseau, clerk-accountant, 400 Merton, St-Lambert, for the following purposes: To carry on business as a real estate ami «\u2022«instruction company, under the name of \"Les Habitations Noël inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1.000 common shares of $10 each and 300 preferrwl shares \"f 1100 each.The head office of the company is at La Sarre.judicial district of Abitibi.Raym«)nd Dor villi:.Assistant Secretary of the Province.17(i05 4421 \"it.Gérald Henry inc.Notice is given that under Part i of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of October, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gérald Henry, contractor, Wood Street, St-Chrysostôme.Hélène Miehaud, 807 Duluth Street East, and Marcelle Cournoyer, 5170, 11th Avenue, the latter two secretaries.611es majeures of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a transport, enterprise ami sub-enterprise company, construction and general development including business as garage keepers, as well as business as a holdiuu.investment, and management company, umler the name of \"Gerald Henry inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 5,000 common shares of a nominal value of $10 each and into 5,000 preferred shares of a nominal value of $10 each. QUEBEC OFF ici AL GAZETTE, December 17, 2000, Vol, 98, No.SO Le siège social «le la compagnie est à St-( hrysostôme, comte «le Cliâteauguay, district judiciaire de Bcauharnois.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.17605-» 3924-00 Immeubles l'uni Dubuc inc.Avis es donné qu'en vertu de la premier» \u2022 partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-irmiverneur de la province a acconlé des lettres patentee, en date «lu 31e jour d'octobre 1906, constituant en corporation : Pierre-Ci.Rouchard, avocat, 3010, boulevard Toupin.St-Laurent.Marcel Hamclin, notaire, 12060, boulevard l.'Acadie, et Claudette Boisvert, secretaire, fille majeure.10142, St-Firmin.ces deux dernière de Montréal, pour les objets suivants: l-'aire affaires comme compagnie d'immeuble, «le construction, de placement et dc portefeuille holding), sous le nom dc «Immeubles Paul Dubuc inc.», avec un capital total de $40,000.divise en 400 actions ordinaires $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 11905.l'ilion.Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire dc la province.Raymond Douvillk.17606m 4073-00 Les Immeubles Raoul Dubord inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies, j'administateur ilu gouvernement de la province a acconlé «les lettrée patentes, en «late «lu 22e jour «le novembre 1966, constituant en corporation: Raoul Dubord.homme «l'affairés, Êliane Rlain, ménagère, épouse «\u2022\"ntra«:tuellement séparée «le biens dudit Raoul Dubord, tous deux «le 150.rue Meunier, et Arthur Bourbonnais, rentier, 1741.rue Dumas, tous trois de Laval, pour les objets suivants: l'aire affaires comme compagnie d'immeuble et de «construction, sous le nom «le « Les Immeubles Raoul Dubord inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 1.000 actions ordinaires «le $5 chacune et en 3.500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 485, boulevard des Laurentides, appartement 2, Laval, ¦listrict judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire dc la prorince, Raymond Douvillk.l7605-e 4227-60 J «Se L Sales Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en «late «lu 3 le jour d'octobre 1900, constituant en corporation: Arthur Yanofsky.Asher Kahn, tous deux avocats, et Grace Blackctt secrétaire, fille majeure, tous trois «le 1, place Ville-Marte, suite 1501.Montréal, pour les objets suivants: Maintenir une organisation «le vente ou d'achat à «les fins «le promotion, de vente, de ré-« laine, de distribution ou introduction de tous «I aucuns des produits manufacturés, sous le nom de « J & L Sales Inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, ¦listrict judiciaire de Montréal.I* Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.17606 4441-00 The bald «>ffice of the company is at St-Chrysostome, county of ChAteauguay, judicial district of Hcauharnois.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.17606 302446 Immeuble- Puni Dubuc inc.Notice is given that uiuler l'art 1 of the Companies Act.letters patent, bearing «late the 31st day of October, 1066, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre-G.Bouchard, lawyer, 3010 Toupin Boulevard, St - Lauren I.Marcel Hamelin.notary.12080 L'Acadic Boulevard, ami Claudette Boisvert, secretary, fille majeure.10142 St-Firmin, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction, investment and holding company, under the name of \"Immeubles Paul Dubuc inc.\".with a total capital stock of $40.000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company is at 11965 l'ilion.Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.17005 40784)6 Les Immeubles Raoul Dubord inc.Notice is given that under Part I «>f the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd «lay «)f November, I960, have been issued by the Arminidtrator of the Government of the Province, incorporating: Raoul Dubord.businessman, Êliane H lain, housewife, wife contractually separate as to property of sai«l Raoid Dubonl.both «>f 156 Meunier Street, and Arthur Bourbonnais, annuitant, 1741 Dumas Street, all three «if Laval, f»>r the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of '*Les Immeubles Raoul Dubord inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 1,000 common shares of $5 each ami 3.5(H) preferred shares of $10 each.The head office of the c«nnpany is at 485 Des Laurentiiles Blvd.apt.2.Laval, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.17605 4227-66 J & L Sales Inc.Notice is given that uiuler Part 1 «>f the Companies Act, letters patent, bearing «late the 31st day of October.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, in-coiporatmg: Arthur Yanofsky, Asher Kahn.both advocates, ami Grace Blackctt.secretary, fille majeure, all three of 1 Place Ville Marie, Suite 1501, Montreal, for the following purposes: To maintain a selling or purchasing organization for the promotion, side, advertisement, distribution or introduction of any and all manufactured products, under the name of \" J & L Sales Inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each ami 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.17605-o 4441-66 6318 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 17 décembre 1966, 98' année, n° ÔO Jeux d'été de Québec 1969 inc.Quebec Summer Cames 1969 Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 21e jour d'octobre 1966, constituant en corporation sans capital-actions: Jean Sirois, 1307, de Fontenay, Michael E.Hickson, 330, Itichclicu, tous deux avocats, Jacques Jolicoeur, comptable, 2155, Mont-Thabor, Rita L.Belleau, secrétaire, épouse contractuellement séparée de biens de René Belleau, 40, des Pins est, Pierrette C.Mignault, secrétaire, épouse commune en biens de Jocelyn Mignault, 265, de l'Espinay, Ribianc Marceau, 30, Ste-Ursule, et Micheline Durand, 315, 9e rue, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, tous sept de Québec, pour les objets suivants: Faire la promotion d'activités de sport amateur et coordonner le travail des sociétés existantes en vue de préparer, organiser et réaliser pour 1969 en la cité de Québec et ses environs, les premiers jeux d'été interprovinciaux du Canada, sous le nom de « Jeux d'été de Québec 1969 inc.\u2014¦ Quebec Summer Games 1969 Inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $10,000,000.Le siège social de la corporation est 10, de Bernières, Québec, district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.17605-o 4295-66 Junior R de The t ford inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de novembre 1966, constituant en corporation sans capital-actions : Robert Girard, gérant, 7e rang, Paul Perron, journalier, 429, rue Ouellet, et Léandre Fradette, commerçant, 457, rue St-Alphonse est, tous trois de Thetford Mines, pour les objets suivants: Former et diriger une ligue de gouret et promouvoir le sport et la culture physique en général, sous le nom de « Junior B de Thetford inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $100,000.Le siège social de la corporation est à Thetford Mines, district judiciaire de Mégantic.Ia1 Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.17605-n 433346 Kcphalê inc.Avis est donné qu'en vertu de la première part ie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en «late «lu 28e jour d'octobre 1966, \u2022 'instituant en corporation: Robert Papineau, 7810, rue St-Denis, Léo Fleury, 4288, rue St-Dcnis, tous deux gérants de crédit, et Lise Roberge, secrétaire, fille majeure, 5507, Jeanne -« l'Are, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «le placement, soils le nom de « Kcphalê inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions pri-vilégiées «le $10 chacune.Jeux d'été de Québec 1969 inc.Quebec Summer Games 1969 Inc.Notice Is given that umler Part III «»ul«- vard Gamelin, Hull, Raymond Relasky.rue VlaeLaren ouest, Ruckinghain, tous trois ingénieurs, et Guy Relasky, technicien.126, boulevard St-Joseph, Hull, pour les objets suivants: Vérifier «'t inapecter le sol.béton ou ciment et tous ses sous-produits et la qualité de toutes sortes f Hull.Raymond Dot vii.i.i:.Issistant Secretary of the Province.17605 3529-66 Lachinc Western Beef lue.Notice is given that umler l'art I «»f the Companies Act, letters patent, bearing «late the 31st day of October, 1966.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Ronald George, meat cutter.Nor-leen Abrams.secretary, wife separate as t«> property «>f Raymond George, both of 4901 Dollanl.Pierrefomls.and Bcrnard-K.Blanchard, advocate, 105, 3rd South Avenue.Roxboro, for the following purposes: To deal in foo«l products, groceries, animal and poultry foods, umler the name of \"Lachine Western Beef inc.\", with a total capital stock «>f $40,000, divided into 3,000 common shares «»f $10 each ami 1,000 preferred shares of $10 each.The hea«l office of the company is at Lachine, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.17605-o 4079-66 René Laflammc assurances inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 26th day of October, 1966.have been issued by the lieutenant-Governor of the Province, incorporating: René Lallanime, insurance broker.Rita Bélair.housewife, wife of said René Laflammc, both of 8405, 5th Avenue, Laval, and Raymond-!.Couture, chartere«l accountant, 421 St-Joseph Boulevard.West, Montreal, for the following purposes: To carry on business an insurance brokers and agents, umler the name of \"René Laflammc assurances inc.\" with a total capital stock «>f $40,000, divided into 3,000 common shares «>f $10 each ami 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Laval, judicial district of Montreal.RaYMON d I >Ol ' ville.Assistant Secretary of the Province.ff17605 4416-66 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 décembre 1966, 98' année, n\" 60 6320 Laiterie Ste-Croix inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenunt- gouverneur de la province » accordé des lettres patentes, en date du 27e jour d'octobre i960, constituant en corporation: Benoit Garneau, Maurice Garneeu, tous deux Initiers, et Lnu- réanna Marion, ménagère, veuve non remariée do Ls-Philippe Garneau, tous trois de 8te*Croix, comté de Lotbinière, pour les objets suivants: Exploiter une laiterie dans toutes ses spécialités, sous le nom de « Laiterie Ste-Croix inc.avec un capital total de $50.000, divisé en 600 actions ordinaires de g] chacune, 4S2 actions privilégiées « A » «le $100 chacune et «'n 1,200 actions privilégiées * B » de $1 chacune.1a' siège social de la compagnie est à Sainte-Croix, comté Lotbinière, district judiciaire de Québec.Le Sotu-êecrétaire de la province, Raymond Douville.I7605-o 408046 Kdgar Lamoureux inc.Avis est donné QJtt'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies, le lieutenant» gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes, en «late «lu 21 c jour d'octobre 1966, constituant1 en corporation: Edgar Lamoureux.homme d'affaires, Lilette Lamoureux, secrétaire, épouse séparée «le biens dudit Edgar Lamoureux.tous deux de 413, boulevard Sauvé.St-Eilstaclic, «\u2022t Maxime Millairc.retraité.Embrun, comté «le Russell, dans la province «l'Ontario.|xiur les objets suivants: Faire le commerce «le tOUS produits, articles et marchandises.SOUS le nom «le « Edgar Lamoureux inc.», avec un capital divisé en 10.000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 5,000 actions privilégiées de 810 chacune.Ia: siège social «le la compagnie est à St-Eustache.district judiciaire de Terrelnmne.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.I7605-O 4277-00 Laval Securities Inc.Les Valeurs Laval inc.Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en «late «lu 27e jour d'octobre 1966, constituant en corporation: John D.Attenbo-rough, technicien.665, 2e Avenue, Philip Murphy, garagiste, 0750, 31e Avenue, et Jean-Marc Richer, notaire, 87, Les Peupliers, tous trois «le Laval, pour les objets suivants: Paire affaires comme compagnie dc placement, «l'immeuble et de construction, sous le nom dc « Laval Securities Inc.\u2014 Les Valeurs Laval Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 3.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Laval, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.I7605-o 3988-00 A.Lecompte & fils inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres Laiterie Ste-Croix inc.Notice is given thut under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of Oetol»er, 1966, have been issued hv the Lieutenant-Governor «>f the Province, in.corpotatingi Benoit Garneau, Maurice Gameau, both milkmen, and Luurcunnu Marion, house-wife, unremarried wi«low of I,s-'Philippe Garneau, all three of Ste-Croix, county »f Lotbinière, f«»r the following purposes: To operate a dairy in all its specialties, under the name of \"Laiterie Ste-Cr«>ix inc.\".with a total capital stock of 160,000, divided into ISOO common shares «)f $1 each.482 preferred \u2022¦ A shares of $100 each ami into 1.200 preferred « B \u2022 shares of $1 each.The head office of the company is at Sainte-Croix, county «>f Lotbinière, judicial district of Quebec.Raymond Dot villi.Assistant Secretary of the Provina 17005 1380-66 Edgar Lamoureux inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 21st day «>f October, 1066, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province, incorporating: Edgar Lamoureux.businessman, Lilette Lamm reux, secretary, wife separate as t«» property of the said Edgar Lamoureux, both «»f 413 Sauvé Boulevard, St-Eustache, and Maxime Millaire.retired.Embrun, county of Russell, in the Province of Ontario, for tin-following purposes: To carry on the business «»f all products articles and merchaiulise.under the name of \"Edgar Lamoureux inc.\", with a capital-stock divided into 10.000 common shares without nominal value and 5,000 preferr«'«l shares of $10 each.The head office of the company is at St-Eustache.judicial district of Terrebonne.Raymond Dor villi;.Assistant Secretary of the Province.17605 4277-66 Laval Securities Inc.Les Valeurs Laval inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of October, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: John D.Attenborough, technician, 605, 2nd Avenue, Philip Murphy, garageman.0750, 31st Avenue, and Jean-Marc Richer, notary, 87 Les Peupliers, all three of Laval, for the following purposes: To carry on business as an investment, real estate ami construction company, under the name of 'Xaval Securities Inc.\u2014 Les Valeurs Laval inc.\", with a total capital stock of $40,006, divided into 3,000 common shares of $10 each and 1,000 preferre«l shares of $10 each.The head office of the company is at Laval* judicial district of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.17605 398846 A.Lecompte & tils inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of October, 1966, have been issue 1 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 17, 1900, Vol.98, So.RO patentes, eii «late «lu 20e jour d'octobre 196(1, '.instituant en corporation: Lucien Lecompte, Léo lAH'ompte, tous deux électriciens, de route rurale numéro 1, Grande-Ile, et Gilford Corley, ¦ .munis, 43, rue Crescent, Salaberry-de-Valley-Beldi POUT les objets suivants: l'aire uffaires comme électriciens, sous le nom de « A.Lecompte & fils inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 2,000 actions ordi-naircs «le $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.be siège social de la compagnie est à Salaberry-vince a accordé des lettres patentes, en «late «lu 21e jour «l'octobre I960, constituant °u corporation sans capital-actions: Bertrand Bourget.mécanicien, Dame 'Bertram! Bourget, institutrice, épouse contractuellcment séparée «le biens dudit Bertram! Bourget.Raymond-Marie Bergeron, mécanicien, Raymond Brassard, employé de bureau.Jacques Vandal, by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Lucien Lecompte, Léo Lecompte, both electricians, of rural route number 1, Grande-Ile, ami Clifford Corley, clerk, 43 Crescent Street, Salabcrry-«le-Yall«\\vfield, for the following purposes: To carry on business as ule«-triciaus, under the name of \"A.Lecompte & fils in«r.\", with a total capital stock of $40,000, divided int«> 2,000 common shares of $10 each and 8(000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Salaberry-f the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of November, 190(5, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Robert Lessard, industrialist.Christine Boucher, housewife, wife of the sai«l Robert Lessard, an«l Jacques Rhéault, technician, all three of St-Wenceslas, for the following purposes: To carry on business dealing in farming implements, farm machinery, motor vehicles and others, under the name of \"Lessard machineries inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at St-Wenceslas, judicial district of Nicolet.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.17005 4424-66 location B.& G.Camping inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 31st day of October, 1966.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Marc-Y.Guay, salesman, Lise Saindon, housewife, wife separate as to property of said Marc-V.Guay, ami duly authorized by him for the presents, both of 52B Jacques-Cartier Street, Lauzon, and Maurice Bouille, salesman, 500, 70th Street West, Charlesbourg, for the following purposes: To deal in and rent trailers, trailer tents ami all other objects or articles serving for camping, under the name of \"Location B.& G, Camping inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 52B, Jacques-Cartier Street, Lauzon, judicial «listrict of Quebec-.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.17005 4433-60 Loisirs de Chute-des-Passes inc.Notice is given that under Part III «»f the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day «>f Oct«»l>cr.1900.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province t«> incorporate a corporation without share capital: Bertraml Bourget.mechanic, Dame Bertrand Bourget, professor, wife separate as tf said Bert rand Bourget, Raymoud-Maire Bergeron, mechanic, Raymond Brassard, office employee, Jacques vandal, Jules Recette, both «»|m>- GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 décembre 1966, 98' année, n° 60 6322 lulei Racette, tous deux « pérateurs, Robert SaaievUlei policier, Hennai Qrenieri employé de bureau, el Berthe Bergeron, ménagère, épouse eontraottiehement séparée de biens d'Edmond Bergeron, tous neuf de Chute-des-Passes, pour It's objets suivants: I.'organisation des loisirs, SOUS lf Roberval.Raymond Dot vii.ii.Is.-i.slant Sccrctari/ of the i'roiim, 17606 3831 (Hi I.c8 Loisirs de Ste-Félieite.comté de L'Islet Notice i- given thai under Part III «t tin-Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day «>f November, 1066, have been issued h\\ the Lieutenant-Governor «f the Province to in corporate s corporation without share capital Clément Duhé, breeder of fowls, Alphonse Mor-neau, farmer, Rosaire Bernier, Raymond st-Pierre, both labourers.IIcrm«''n«''gil Vaillancourt, merchant, Mrs.Xavier Fortin, housewife.Félix Pelletier, ïv louai» I-A.Pelletier, Loth joiiu'n», Mrs.FrédéricCliouinard, housewife,and Léonard Pellerin, mecluuùc, all ten «»f Ste-Féeilité, county of L'Islet, for the following purposes: The organisation «>f recreational activities, under the name «>f \"Ix-s Loisirs l the Companies Act.letters patent.Iicuring date the 27th day «>f October, 1966.have been issued by the Lieutenant-Governor «»f the Province t incorporate a corporation without share capital: Jean-Yves Couillnrd.farmer.Roger Comtois, contractor, ami Conrad Handheld, inn-keeper, all three of St-Marc, f«>r the following purposes: The organization of recreational activities, under th«' name of \"Les Loisirs «le St-Marc'.The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is 815,000.The head office of the corporation is at St-Marc, judicial «listrict of Richelieu.Raymond Dot villi:.Assistant Sccrctari/ of the Provint; .17605 4309-66 Louvon construction inc.Notice is given that umler Part 1 of tlw Companies Act, letters patent, bearing «laie the 26th day «»f October, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating : Yvon Ménard, builder, 6535 Gouin east.Montreal-North, Yvonne Ménard, personnel supervisor, fille majeure, 2 Marois Blvd., ami Louis-Marie Leclair.administrator. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 17, I960, Vol.98, No.SO 6323 Leclair, administrateur, 684, boulevard «!% Prairies, ces deux derniers de Luvid, pour les objets suivants: PailY affaires connue constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de * LoUVOD construction inc.-, avec un capital total de 840,000, divisé i-n :ioo actions ordinaires ¦le 1100 chacune et en 100 actions privilégiées de SI 00 chacune.Le siège social de la compagnie est 6535, (¦oniu est, Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.I.e So us -sécréta ire de la province.Raymond Douville.I7605*o 4351-66 Bernard Lussier inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour d'octobre 1066, constituant en corporation: Bernard Lussier, pharmacien) Claudette Lussier, ménagère, épouse dudit Bernard Lussier, tous deux de 105.Les Plaines.Laval, et André Brièrc, vendeur, 135, rue Sherbrooke est.\" Montréal, pour les objets >uivants: Paire affaires comme compagnie de placement, sons |e nom de «Bernard Lussier inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,900 actions privilégiées de $10 châtaine.Le siège social de la compagnie est à St-Eus-taehe.district judiciaire «le Terrelwnne.I.r Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.I7605-o 4387-66 A.Lustig Inc.Avis eat donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé «les lettres patentes, en «late «lu 3e jour de novembre I960, constituant en corporation: Georges-Henri Du-rcault, avocat, Christianc Rochette, ménagère, épouse contractuellement séparée «le biens dudit G«3orges-Henri Dureault, et «lûment autorisée par ce dernier aux fins «les présentes, tous deux de \u2022'!).rue Elgin, et Micheline Malien, secrétaire, épouse contractuellement séparée «le biens de Germain Fontaine, et «lûment autorisée par ce dernier aux fins «les présentes, 602.rue Mercier, tons trois «le Granhy, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le couvre-planchers, tapis, linoleum, tuile de toute description, sous le nom «le « A.Lustig Inc.», avec un capital total f 8100 each ami 100 preferred shares « f $100 each.Tile head office of tl»' company i> at 6535 Gouin east, Montreal-North, judicial district nt ractuellement séparée de biens dudit Lorenzo Camirand, tous deux de Notre-Dame-du-Bon Conseil, et Gilles Camirand, vendeur, 188, St-Pélix, Drummondville, pour les objets suivants: l'aire affaires comme meuniers et faire le commerce de grains et céréales et des produits de la terre et leurs sous-produits, sous le nom de « Meunerie Camirand inc.», avec un capital total «le \u2022fit1,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune, 380 actions privilégiées classe «A » «l'une valeur nominale «le $100 chacune et en 1,000 actions privilégiées «\u2022lasse « B » d'une valeur nominale de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, district judiciaire de Drummond.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.I7605-O 4222-00 Mont-Yalin Aviation inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la \\aà «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé «les lettres patentes, en «late «lu 2(k' jour «l'octobre 1900, constituant en corporation: Maurice (îravel, architecte, 306* «le l'Assomption, Marins Bou-«Ireault, journalier, 204, rue Gravel, et Paul-Henri Tremblay, courtier en immeuble, 400, rue Delisle, tous tniis «le Chicoutimi.pour les objets suivants: St-Joseph Blvd.Montreal, for the following purposes: To carry on business as auctioneers, under the name of \"Les Marchés «l'animaux Drummond, ltée\".with a total capital stock of 6100,000, divided into I .(KM) common shares of $10 each and 9.000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Wendover, and Simpson, judicial district of Drummond.Raymond Doi'ville.Assistant Sccrctari/ of the Province.17605 430K-66 Mar-I.ao inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day «)f November, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Léo-Paul Landry, administrator, Gertrude Martin, housewife, wife separate as to property of said Léo-Paul Landry, ami Marguerite Gingras, housewife, wife separate as to proterty of Roger Désilets, all three «>f Nicolet, for the following purposes: To carry on business as a transport company and to ileal in merchandise t>f all kinds, under the name of \"Mar-Lan inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each an«l into 200 preferred ¦bates of $100 each.The bead office of the company is at Marie-Yictorin Route, Bécancour (St-Grégoire), judi-« ial district of Nicolet.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.L7605 4508-06 Meunerie Camirand inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th «lay of December, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province in-r the following purposes: To carry on business as millers and to deal in grain and cereal and products of the land and their by-products, under the name of \"Meunerie Camirand inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 cummon shares of a nominal value of $1 each, 380 preferred class \"A\" shares of a nominal value of $100 each ami into 1,000 preferrefl class \"B\" shares of a nominal value of $1 each.The head office of the company is at Notre-Dame-du-Bon-Conseil, judicial district of Drummond .Raymond Doi ville, Assistant Secretary of the Province.17605 4222-66 Mont-Yalin Aviation inc.Notice is given that umler Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 26th day of October, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Maurice Gravel, architect, 396 «le l'Assomption, Marins Bomlreault.ilay labourer.204 Gravel Stnet, and Paul-Henri Tremblay, real estate broker, 4(M) Delisle Street, all three of ClnVoutimi.for the following purposes : 0326 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 décembre 1966, 98' année, n° 60 Etablir «'t maintenir ties lignai ou servit-os aériens réguliers et des moyens de transport de toutes sortes, sous le nom de « Mont-Valin Aviation inc.avec un capital total de 8150,000, divisé eu 5,000 actions ordinaires d'une valeur nominale «le 110 ebacune et en 10,000 actions privilégiées d'une valeur nominale «le Sio chacune.lx' siège social de la compagnie est à Chicou- timi.«listrict judiciaire de ('liicoutimi.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doiville.17005-.) 4078-66 Motel Carignan inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi d«is compagnies, le lieutenant-gouverneur «!«' la province a accordé «les lettres patentes, en date «lu 26e jour d'octobre 1866, constituant en corporation: Y van Macerola, 2S05.Marquette, .lames (ialileo, 1007, Massenet, tous «leux de Laval, et Bruno Paterae, 11818, Prigon, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exploiter «les hôtels, motels, restaurants, boutiques, appartements, cabines et tous genres d'habitations, sous le nom de « Motels Carignan inc.», avec un capital total de $45,000, divisé en 2,000 actions ordinaires «le $10 chacune et en 250 actions privilégiées «le $100 chacune.Ix' siège social de la compagnie est boulevard St-Luc, St-Lue.district judiciaire f $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial «listri«-t of Montreal.Raymond Doi villi.Assistant Serretan/ of the I'rovinn .17605-o 4210-66 P.Ruscito construction ltéc Avis est donné qu'en vertu «le la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour d'octobre 1901), constituant en corporation: (Maude Boisvert.avocat, 1505, Moore, Laval.Yolande Poliseno, 555, Yilleray est, Montréal, et Louise Delormc.350, avenue Pine, St-Lainbcrt, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom «le « P.Ruscito construction ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «le $1 chacune et en 3,900 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district, judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.17605-0 4419-00 P.Ruscito construction ltéc Notice is given that under Part I «>f the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of October.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Claude Boisvert.advocate.1506 Moore, Laval.Yolande Poliseno, 555 Yilleray East, Montreal, and Louise Delormc.350 Pine Avenue, St-Lambert, the latter two secretaries, filles majeures, for the following purposes To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"P-Ruscito construction ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 3.900 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the I'rovinee.17005 4410-86 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 17, 1966, Vol.98, No.60 K.St-Aubin Parcel Delivery Inc.Avis est donné qu'on vertu do la première partie (le lu Loi «les compagnies, le lieutenant -gouverneur «le lu province a acconlé des lettres patenteii en «late «lu 27e jour d'octobre I9(j*>, .un-tituaiit en corporation: Maurice Déry, Levis GagUOU, tOUI deux notaires.ilf the Province, incorporating: Maurice Déry, Levis (iagnon.both notariée, f 8052 St-Michel Boulevard, St-Michel, and Emile St-Aubin.industrialist.2584 \\ illeray.Montreal, for the following purposes ; To carry on business as a transportation company, umler the name of \"K.St-Aubin Parcel Delivery Inc.\", with a total capital stock rin, ces «leux «lerniers de Tracy, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «le placement, sous le nom «le « La Société d'Angoulème inc.», avec un capital total de $50,000, divisé en 100 actions onlinaires «le $1 chacune et en 499 actions privilégies de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Tracy, «listric't judiciaire de Richelieu.Le Sous-sécréta ire de la province, Raymond Dor ville.1700ô-o 4269-00 31st day of October, 1900, have been Issued by the Lieutenant-Governor of the Province, in.co rpi ira ting: Joseph Pliinsoll S ma 11 wood, managing director, 5100 Mariette, Léo-A.Saint-Pi.rre, lawyer, 7110 Somerled Avenue, both of Montreal, and John II.Markham, creative director, 1500 ChAteauguay, Chambly, for the following pur.I m jses : To carry on the business of a general advertising agency in all its branches, under the name of '*Smallwoof t be Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of October, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, iu-«¦orporating: Jean Brossard, notary.St-Rémi, county «)f Xapierville, Jean-Pierre Brossard, stwlent.ami Marie-Josée Brossard, student, fille majeure, the latter two of 3575 Marlowe Avenue, Montreal, for the following purposes: To «leal in all kinds of shoes ami slippers as well as leather, plastic articles and their accessories, under the name of \"Southern Slippers (1900) Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,500 common share* of $10 each ami into 2.500 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at St-Hémi, county of Napierville.judicial district «>f Iberville.Raymond Dor villi.Assistant Sccrctari/ of the Province.17605 4108*68 Les Spécialités B.C.Dec Notice is given that under Part 1 i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour d'octobre 1960, constituant en corporation: Adrien-R.Paquette, 212, Rloomfield, Outremont.Marcel Paquette, 1320, Chanteclerc, St-Bruno-de-Montarville, tous deux avocats, et Micheline Pilotte, secrétaire, fille majeure, 0727, Charlevoix, Montréal, pour les objets suivants: Transland Transport Ltd.Notice is given that uiuler Part 1 of the Companies Act, letters patent, bearing «lat«- the 31st day of October.1060, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province, incorporating: Adrien-R.Paquette, 212 HIoomhYhl.Outremont.Marcel Paquette.1320 Chanteclerc, St-Bruno-uo-vitoh, 4548 Ninth Street, Laval, and Mendel Shifman, 5031 Jeanne-Maiwe, Montreal, the latter three operators, f«»r the following purpos«'.s: To deal in garments made of leather, synthetic or natural materials «>f every nature and kind, under the name of \"Vêtements Opera (Québec) ltée-\u2014Opera Garment (Quebec) Ltd.\".with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares «if a par value «»f $1 each ami 30,000 preferred shares f a par value of 81 each.The head office «»f the company is at 8380 St-Luwrence Boulevard, Montreal, judicial district «»f Montreal.Raymond Doi;ville, Assistant Secretary of the Province.17005-o 4386-66 Vulcanisation St-Laurent inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 2nd day of November, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Guy St-Laurent, 787 de la Falaise Street.Yvon Perreault.721 Bosse Street, both industrialists, and Paul Rondeau, accountant, 984 Marest Street, all three of Hauterive, for the following purposes: To vulcanize, retread or re-sole tires and to \u2022leal in automobile accessories, under the name of \"Vulcanisation St-Laurent inc.\".with a total capital stock of $50,000, divided into 250 common shares of $100 each ami into 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 303 Bossé Street, Hauterive, judicial district of Hauterive.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.17605 4429-66 White Acres Limited Notice is given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of October.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor porating: Michel Pharand, 33 Jolicoeur StreeL Pierre Taché, 14 Place Bélisle, both of Hull, and Charles-B.Major, Lucerne, all three lawyers, for the following purposes: To carry on the business of a real estate ami construction company, under the name of \"White Acres Limited\", with a capital stock divided into 3,000 common shares without par value and 39,000 preferred shares of the par value of $1 each. 0888 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 17 décembre 1966, US' année, n° 50 I.e siège social de la compagnie est à route rurale 3, Wakefield, district judiciaire de Hull.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.17605 4846-66 \\\\ in a nt Enterprises l.id.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de novembre 1066, constituant en corporation: Sandra Sheinfeld.0742, De Vimy, AniectaO'Grady.4012, Hampton toutes deux sténographes, célibataires, et Edward Winaut.administrateur.0.chemin Albion, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie «le placements et d'immeubles, sous le nom «le « Winant Enterprises Ltd.».avec un capital total «le $40,000.divisé en 100 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le $100 chacune et 30.000 actions privilégié«'s d'une valeur au pair de $1 chacune.I.e siège social de la compagnie est à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.I.e Sous-secrétaire de la province.Raymond Douville.17005 4410-00 The head oliiee of the company is ut Rural Route 3, Wakefield, judicial district of Hull.Raymond Dou villi.Assistant Secretary of the Provinc .I70O5-*.4846-68 Winunl Enterprises Ltd.Notice is given that uiuler l'art 1 «»f the Companies Act.letters patent, bearing date tin- 2nd day of November, 1006, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Suudra Sheinfeld, 6742 De Vimy, Aniceta O'Grady, 4012 Hampton, both iteno graphers, spinsters, and Edward Winanl.executive, 0 Album Road, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate ami investment company, under the name of \"Winant Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of SKI.lion, divided into 100 common shares having a par value of $100 each and 30,000 preferred snares having a par value of $1 each.The head office «>f the company is at Montreal, jmlicial «listrh't «>f Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.17606-o 4410-66 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Anglo-Canadian Telephone Company Avis est donné qu'en vertu de la première parti»' «le la Loi dee compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes supplémentaires en date du 20 e jour de novembre 1066, à la compagnie * Anglo-Canadian Telephone Company v.ratifiant la résolution «les administrateurs «lu 29 novembre 1900, relativement à la désignation avant l'émission de 1S0.000 actions privilégiées au taux «!«\u2022 $3.15 «le $50 chacun»'.Le Sous-sccrétairc de la province.Raymond Dou villi;.17606m 2378-34 \u2014 1340/23 Auto Hudson Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accorde des lettres patentes supplémentaires en date du 1 le jour de novembre 1966, à la compagnie « Fredon Ltd.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 9e jour de février 1961, changeant son nom en celui de « Auto Hudson Inc.».Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.17605 10803-61 \u20141343/123 Philibert Bédard (limitée) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 28e jour d'octobre 1960.à la compagnie < Philibert Bédard (limitée) », augmentant son capital de $20,000 à $99,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 290 actions ordinaires de $100 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le Sous-secrétairc de la province, Raymond Douville.17606m 3739-39 \u2014 1343/29 \\nglo-Canadian Telephone Conipunx Notice is given that, under Part I \"f the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day «»f November, 1906, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Anglo-Canadian Telephone Company\", ratifying the resolution of tile directors on November 29.1066, in relation t«> th«' designation In-fore the issuing of ISO.00(1 preferred shares of $50 each at a rate «»f $3.15.17005 Raymond Douville, .Issistani Secretary of the Province.2378-34 1346/23 Auto Hudson Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 11th day of November.lOtiti.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Fredon Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 9th day of February.1961.changing its name to that of \"Auto Hudson Inc.\".Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.17605-o 10803-61 \u2014 1343/123 PhUibert Rédard (limitée) Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of October, 1966» have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Philibert Bédard (IimitéeV.increasing its capital stock from $20,000 t«» $99,000, the additional share capital being divided into 290 common shares of $100 each and 500 preferred shares of $100 each.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.17605 3739-39 \u20141843/29 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 17, 1966, Vol.08, No.SO 6339 Pearl Berger Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-uoiiverneur «le la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du Se jour de novembre 196(5.«V la compagnie « William Berger l.td.'.constituée par lettres patentes en date du 17e jour de novembre 1944, 1° changeant sou nom en celui de « Pearl Berger Enterprises Ltd.; J étendant ses pouvoirs; 3° convertissant et Subdivisant ses 200 actions ordinaires de $100 chacune en 19,000 actions catégorie « A » de $1 chacune et 1,000 actions catégorie » B» de $1 chacune.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.17(H).') 6706-44 \u2014 1343/64 A.Brault & fils ltée A.Brault & Sons Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouveilieur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 31e jour d'octobre 1066, à la compagnie « A.Brault & lils ltée A.Brault & Sons Ltd.», 1° convertissant ses 4,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune en 4.000 actions classe « A » d'une valeur nominale de $10 eba-< une: 2° augmentant ion capital de $40,000 à $300,000, le capital-actions additionnel étant étant divisé en 0,000 actions classe « A d'une valeur nominale de $10 chacune, 10,000 actions classe « B » d'une valeur nominale de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune; 3° changeant le nombre de ses iidministrateurs de 3 à ô.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.I7606-O 12002-51 1343/31 Centre culturel du vieux Montréal Avis est «tonné qu'en vertu «le la Loi «les compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province, des lettres patentes supplémentaires en date «lu 10e jour de novembre 1968, à la corporation « Théâtre «le l'Ancienne Bourse .constituée en corporation jwir lettres patentes «lu 20e jour «le juin 1900, changeant -on nom en celui «le « Centre culturel du vieux Montréal .Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.17606m 2019-00 - 1343'124 Centre récréatif de l'Ancienne Bourse inc.Avis est donné qu'en vertu «le la premier»-partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes supplémentaires en date du 10e jour de novembre 1900.à la compagnie < Centre Culturel «lu vieux Montréal inc.», constituée cil corporation par lettres patentes en date «lu 20e jour «le juin 1960, changeant son nom en celui «le « Centre récréatif «le l'Ancienne Bouree inc.Ije Sous-seerétaire de la province.Raymonii Douville.17606 2018-00-1343/126 Coterive construction ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé «les lettres Pearl Berger Enterprises Ltd.Notice is given that, under Part 1 of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 8th day of November, 1960.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"William Berger Ltd.\", incorporated by letters patent «late«l the 17th f the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 10th day «>f November, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province to \"Stamplcman Holdings Inc.\".incorporated by letters patent dated the 4th day of February, 1903.changing its name to that of \"Nanart Inc.\".Raymond Douvillk.Assistant Secretan/ of the Province.17605m 548-03 1344/4 Pavilion Georges-Frederic Notice is hereby given that in pursuance to the Companies Act, the Lieutenant-Governor of th«- Province has granted supplementary letters patent dated the 3rd day «>f November, 1900, to \"Le Centre d'AcCUed «le Drummomlvillc inc.\".incorporated by letters patent dated the 23nl day of Man-h.1905, i.changing its name into 0342 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 décembre 1966, 98' année, n° 50 1° changeant Mm dou en celui de «Pavillon (îcurgcs-Frcdcric ; 2° modifiant ses |>ouvi>irs.i.e Sous-secrétuire de la province, Raymond Douvillk.17606-0 1231-65 1343/02 Les Placements ViUe-Marie limitée Avis est donné qu'en vertu de lu première partie , à la compagnie « Automotive Remanufac.turers Ltd.», constituée par lettres patentes en «late du 17e jour «le juillet 1902.changeant son nom en Celui «le « Reid Electric & Equipment Ltd.».Sous-secrétairc de la province, Raymond Douville.17005 12968-62 \u2014 1344/8 Selden Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes supplémentaires en «late du 2e jour «le novembre 1900, à la compagnie « J.S.Ilewson Construction Ltd.», constituée par lettres pa- thatof \"Pavillon (ïeorg«'.s-Fre«leri«'\"; 2.amending its powers.Raymond Douville.Assistant Sccrctari/ of the Province.17605 1231-05- 1343/92 Les Placements VUle-Marielimitée Notice is given that, under Part 1 of tin Companies Act, supplementary letters patent bearing «late the 31st day of October, 1966, have been issued by tin- Lieutenant-Governor f the Province t«> \"Les Placements Ville-Marie limitée\", 1.increasing its capital stock from $40,000 to $100,000, the additional share capital being divided into 3,500 common slum's «>f $10 each ami 2.500 preferred shares of $10 each; 2.extending its powers; 3.amending the privileges end restrictions attached to existing preferred snares.Raymond Douvillk.Assistant Sccrctari/ of the Province.17005 103844 \u2014 1343/4\") Quebec Marble Tile Machinery Supply (Quemar) Limited Notice is given that, umler Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 7th day of November.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Quebec Vibrator Tools ami Etpiipment Limited\", incorporated by letter!! patent dated the 23rd day of September, 1957, 1.changing its naine to that of \"Quebec Marble Tile Machinery Supply (Quemar) Limited''; 2.extending its powers.Raymond Douvillk, Assistant Secretan/ of the Province.17005 12495-57 - 1343 7\" Quebec Packers Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 14th day of November.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Edren Enterprises Inc.*.incorporated by letters patent dated the lstli day of March.1900, changing its name to that of \"Quebec Packers Inc.\".Raymond Douvillk.Assistant Secretan/ of the Province.17005-o ' 984-66\u2014 1341 7 Reid Electric & Equipment Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 3r«l day of November.1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Automotive Remanufaeturer> Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 17th day of July, 1902.changing its name to that of \"Reid Electric & Equipment Ltd.\".raymond Douvillk.Assistant Secretan/ of the Province.17605m 12968-62 \u20141844 8 Sclden Limited Notice is given that, under Part 1 of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 2nd day of November, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"J.S.Hewson Construction Ltd.\", incorporate*! by letters patent dated the QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, December 17, I960, Vol.98, No.60 6343 tentes en date «lu 14e jour «le «h'-cemhre 19(H), changeant son nom en celui «le « Selden Limited ».Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.17606 1524-60\u20141344/10 Tomasso Corporation Avis ait donné qu'en vertu «le la premier» \u2022 partie «le la Loi «les compagnies, le lieutcnant-gOUVerneUf «le la province a accord»' des lettres patentes supplémentaires en date du 3e jour de novembre 1966, à la compagnie « Tomasso Corporation , modifiant les privilèges et restrictions attachés à ses actions privilégiées.Le Sous-secrétaire dc la province, R a y m on 0 I >ou ville.17605 14639-58\u2014 1341/40 Cibson Will«Higli!>y (Quebec) Inc.Avis est donné qu'en vertu de lu premier»-partie de la Loi des compagnies, le lieutenant -gouverneur «le la province a acconlé des letttvs patentes supplémentair«\\s en date «lu 4c j«»ur «le novembre 1966, à la compagnie \"Gibson Bros.(Quebec) Inc., constitué par lettres patentes en date du 31e jour de janvier 1962, 1° changeant son nom en celui «le « Gibson Willoughby (Quebec) Inc.»; 2° réduisant son capital «!«¦ $40,000 à $10,000, Je capital-actions annulé étant divisé en 24,000 actions privilégiée* d'une valeur au pair «le 81 chacune.Le Sous-sccrétairc de la province, Raymond Douville.I760S 10106-62 \u2014 1343/84 14th day of December, 1960, changing its name to that of \"Sehlen Limited\".Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.17605* 15624-60 \u2014 1344/10 Tomasso Corporation Notice is given that, uiuler l'art I of the Companies A«:t, supplementary letters patent, b««aring «late the 3rd day of November, 1966, have been issued by the Licutcnuut-Governor «>f the Province to \"Tomasso Corporation\", modifying the privileges and restrietioas attaching to its prefem-d shares.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.17605-«) 1463046 - 1344/40 Gibson Willoughby (Quebec) Inc.Notice is given that, under Part I of the ( Companies Act.supplementary letters patent, bi'aring date the 4th day of November, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Gibson Bros.(Quebec) Inc.\", incorporated by letters patent dated the 31st day of January, 1962, 1.(hanging its name to that of \"Gibson Willoughby (Quebec) Inc.\"; 2.reducing its capital from 840,000 to $10,000, the capital stock annulled being divided into 24,000 preferred shares of a par value of $1 each.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.17605-O 10166-62 - 1343/84 Arrêtés en Conseil Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 2342 Québec, le 30 novembre 1960.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.\u2022 on cernant le classement «l'objets mobiliers -\u2022I art distiques appartenant à la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours de L'Islet.ii.est ordonné, sur la proposition du Ministre des Affaires culturelles: Qua soit approuvé le classement comme objets mobiliers et artistiques, fait par résolution «le la Commission des monuments historiques «lu Québec, en date du 31 octobre 1966, du consentement «lu propriétaire, des objets mobiliers suivants, savoir: «/) Orfèvrerie: Encensoir en argent, de Laurent Amyot, vers 1791 ; Lampe du sanctuaire en argent, l'i.niçois Ranvoyzé (1779); Boîtier aux saintes huiles, François Ranvoyzé; Ciboire en argent.François Ranvoyzé, (1782) style français, milieu du XVille s.; Bénitier en argent.François Ranvoyzé, (1810); Calice en argent, François Ranvoyzé, (1810); Ciboire en or, François Ran-voysé, (1810); Calice en or, François Ranvoyzé.(1310); Ostensoir en or, François Ranvoyzé.(1812); Encensoir en argent, François Ranvoyzé.(1814-1826); Navette en argent, François Ran-voysé, (1814-1826); b) Peintures: L'Annonciation, Créquy, (1776); b«\" Christ prêchant, Louis Dulongpré, vers 1810; Le SiM-ré-Coeur, Louis Dulongpré, vers 1810: Portrait de l'abbé François-Xavier Delage, curé Orders in Council Order in Council Executive Council Chamber Number 2342 Québec, November 30, 1966.Present: The Lieutenant-Governor in Council.CoNCERNiN»; the classification of moveable and artistic objects belonging to the Fabrique of the Parish of Notre-Dame de Bonsecours, of L'Islet.It is ordered, upou the recommendation of the Minister of Cultural Affairs: That the classification as moveable and artistic objects, made by resolution of the Quebec Historic Monuments Commission on October 31.1966, with the consent of the proprietor, of the following moveable objects, be approved, to wit : (o) Silverware: Silver censer, by Laurent Amyot, circa 1791; Silver Sanctuary Lamp, François Ranvoyzé (1779); Case for Holy Oils, François Ranvoyzé; Silver Ciborium, François Ranvoyzé, (1782), French style, middle of XVIIIth century; Silver Holy-water basin, François Ranvoyzé, (1810); Silver Chalice, François Ranvoyzé, (1810); Gold Ciborium, François Ranvoyzé, (1810); Gold Chalice, François Ranvoyzé, (1810); Gobi Monstrance, François Ranvoyzé, (1812); Silver censer, François Ranvoyzé, (1814-1826); Silver Incense-box, François Ranvoyzé, (1814-1826) ; (b) Paintings: The Annunciation.Créquy, (.1776); Christ preaching, Louis Dulongpré, circa 1810; The Sacred Heart, Louis Dulongpré.circa 1810; Portrait of Father François-Xavier 684 4 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 décembre 1966, 98' année, n° ôO «le L'Islet, Eugène Humel, ( 1S87); La Vierge de douleur, A.Plamondon, (1871) copie; L'Imiuu-culée Conception, A.I'laiuondon, (1871) copie; Le Christ en croix, Pierre-Paul Prud-hon, A.Plamondon.copie; La Suinte Famille de François 1er, A.Plamoudon, copie; Saint Louis, Charles Le Brun, A.Plamoudon, (1872), copie; Le Christ mort, A.IMumondon, (1872); c) Sculjitures: Retable du sanctuaire, d'après Ramsay Traquair, oeuvre de Jean et Pierre-Florent Baillargé, commencé eu 1782; ltétable de la chapelle, Ainaldc Charron (1816*1825); Tombeau d'autel et ses sculptures, François Leinieux, (1827); Qui: le présent décret soit publié dans la Gazette officielle de Québec et ait force de loi à compter «le la date «le sa Dublicatum.Copie cooiorme.IjC Greffier du Conseil Exécutif.17617-0 Jacqi'ks Prkmont.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Executif Numéro 212(5 Québec, le 16 novembre I960.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en e«mscil.Concernant la réduction «lu montant «h* la rente et «lu r the first year and 50% for each subsequent year the amount of the rental and the cost «>t' the required work, if it holds five or more COntigUOtUi licences of a total area of at least 250,000 acres in the electoral districts of Rimouski, Mata-pédia, Matane, Caspé-North, Gaspé-Soutb.Bonaventure ami the Magdalen Islands, the I slant of Anticosti.the territory of Abitibi and New Quebec; Whereas the aforementioned five (5) licenses are all situated in the electoral «listrict of Gaspé-South and have a total area «»f 287,800 acres; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Natural Resources: That, pursuant to section 144 of the Mining Act (13-14 Elizabeth 11, chapter 34), the amount of the rental and the cost of the require\" 1 srorks be reduced to the extent of 75% for the first year and 50% f«>r each subsequent year relative to exploration licenses numbers 218 t«» 222 inclusively, granted to the Société Les Pétroles Laduboro Limitée and covering an urea \"I 287,800 acres: That this regulation have the force i, l'avis «le réduction des gains a«lmissiblcs non ajustés se fait en adressant au cotisant, p»r la poste à sa dernière adresse connue, un état corrigé.Demande de réexamen 2.03 Toute demande «le réexamen en vertu des articles 194.201 et 203 de la loi doit se faire sur la formule prescrite et contenir les moyens invoqués au soutien «le la demande.Renseignements confidentiels -.1)1 Lorsqu'un cotisant, OU un bénéficiaire \"ii 'ii représentant dûment autorisé demande, sur la formule prescrite adressée à la Régie, qu'un renseignement obtenu en vertu «le la présente loi sur ce cotisant ou ce bénéficiaire soit communiqué à toute personne désignée dans la demande, ce renseignement ne peut être communiqué que s'il s'agit d'un renseignement relatif Su montant initial de la prestation payable ou a la date où débute le paiement de cette presta- Order in Council Executive Council Chamber Number 2243 Québec, November 24, 1966.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the Quebec Pension Hoard.It is ordered, upon the recommendation of the Minister of Finance: That be approved, under the authority of section 227 of the Quebec Pension Plan (13-14 Elizabeth II, chapter 24), in its French and English versions, the regulation adopted by the Quebec Pension Board at its meeting of November 11, 1966, and of which a copy is joined to the present Order in Council; That this regulation will come into force only after its publication in the Québec Official Gazette.True copy.Jacques Prémont, Clerk of the Executive Council.Quebec Pension Board Regulation respecting benefits Division I Definitions atui application 1.01 In this Regulation, the following expressions mean: (a) \"Act\": the Quebec Pension Plan; (6) \"Board\": the Quebec Pension Board.Division II Administration Statement from the Record of Earnings 2.01 Pursuant to section 200 of the Act, a contributor may obtain a statement of the unadjusted pensionable earnings shown to his account in the Record of Earnings, including the unadjusted pensionable earnings shown to his account in the Record of Earnings established under the Canada Pension Plan, by filing with the Board a written application to this effect.In such application, he shall state his name, address, social insurance number, and the date he last made such an application.2.02 For the purposes of section 203 of the Act, a contributor shall be notified of any reduction in the amount of his unadjusted pensionable earnings by mailing a corre ted statement to him at his last known address.Request for Reconsideration 2.03 Any request for reconsideration under sections 194, 201 and 203 of the Act shall be made on the prescribed from and state the reasons thereof.Privileged Information 2.04 Where a contributor or beneficiary or authorized representative of such person applies to the Board on the prescribed form to have any information obtained under this Act with respect to such contributor or beneficiary communicated to any person named in such application, no such information shall be so communicated except in respect of the basic amount of a payable benefit, or the date from which such benefit is payable, or in respect of 0340 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 décembre I960, 98' année, n° 50 lion, ou un montant «les gains admissibles non-ajustés |M»rtés au registre des gains.2.05 Nonobstant l'article 2.04.la Régi»' petit refuser de fournir le renseignement demandé lorsque la personne désignée est un créancier do cotisant ou «lu bénéficiaire, ou un («présentant «h- ce créancier.Gains et contributions en rertu d'un régime equivalent 2.011 Pour les fins du paragraphe 2° de l'alinéa In de l'article 112 «le la loi.les montants «les gains et des contributions d'un cotisant en vertu «lu Régime «le Pensions «lu Canada sont l«-s montants déterminés selon les dispositions de «\u2022ù la demande, sur la formule prescrite complétée par le requérant OU en son nom, est reçue à un bureau «le la Régi»'.3.03 Tant que le requérant n'a pas été avisé par la Régie «pie le paiement d'une prestation a été autorisé, il peut annuler sa demande en avisant par écrit la Régie à cet effet.Mais si le requérant a été ainsi avisé par la Régie, il peut annuler sa demande en faisant parvenir à la Régie la formule prescrite à cet effet.Cependant, la «!eneficiary in the month when lie reaches the indicated age.Where a benefit becomes payable in a month other than the month of the beneficiary's birthday, the commuted value shall be determine*I by extrapolation. 0348 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 décembre 1966, 98* année, n° 60 Recouvrement 3.16 Lorsqu'une personne a reçu le paiement d'une prestation auquel elle n'avait pas droit.ou reçu un paiement de prestation supérieur à eellti auquel elle avait droit, et «pie ce paiement ou cet excédent de paiement n'a pas été recouvré par d'autres moyens, la Régie peut retenir toute prestation payable au bénéficiaire ou peut déduire Cet excédent des versements de prestations subséquents de la manière qu'elle jupe rai-m Humble selon les circonstances.Skctiox IV Rente de retraite Demande 1.01 La demande d'une rente de retraite ne peut être faite plus de trois mois avant la «late où elle est payable.4.02 Le requérant d'une rente de retraite doit produire à la Régie une déclaration indiquant le montant de son salaire admissible et «le ses gains admissibles «l'un travail autonome pour l'année au cours de laquelle la demande est faite et.à la demande de la Régie, celui f each year the amount of his employment earnings ami their source on the prescribed form, for each month of the preceding calendar year.Reduction of Pensions 4.06 Every year the Hoard shall determine whether the retirement pension received by a beneficiary in the eourse of the preceding year is to be reduced pursuant to sections 170 and 171 of the Act.4.10 Where it appear- that an overpayment, has been made t«» the beneficiary, such overpayment shall be recovered in accordance with section 8.16.Suspension of lienefits 4.11 The Board may suspend the payment of any retirement pension during an investigation as to the eligibility of the beneficiary or pending the determination of his employment earnings.4.12 In respect of section 4.11, the Board shall forthwith notify such beneficiary of any such suspension, and the Board shall, with all due despatch, proceed with the required investigation and notify the beneficiary of its decision.Certified copy.Gill Eortier, 17648-o Secretary.Order in Council Executive Council Chamber Number 2244 Québec, November 24, 1966.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the Quebec Pension Board.It is ordered, upon the recommendation of the Minister of Finance: That, under the authority of section 227 of the Quebec Pension Plan (13-14 Elizabeth II.chapter 24), in its French and English versions, the regulation adopted by the Quebec Pension Board at its meeting on November 15, 1966, a copy of which is annexed to the present Order in Council, be approved; That this regulation come into force only after its publication in the Québec Official Gazette.True copy.Clerk of the Executive Council.Jacques Prémont, 9J80 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 décembre 1966, 98' année, n° 60 RÉGIE DES RENTES du QuÉHEC Règles de -procédure de lu Commission de revision Application 1.Les présentes règles Hxent lu procédure «lu pourvoi «levant lu Commissionde revision, prévu à l'article 190 de la loi.2.La Commission d'appel des pensions est le tribunal (pli agit comme Commission de revision, conformément à l'arrêté en conseil numéro 911, édicté le 18 mai I960 sou l'autorité de l'article 229 de la loi.Définitions 3.Dans les présentes règles, les expressions suivantes signifient: a) «loi»: le Régime de rentes du Québec; 6) « appel » : le pourvoi en revision prévu à l'urticle 190 de la loi; c) « ( oinmission \u2022\u2022¦ : la Commission d'uppel des pensions; d) « président \u2022 le président de la ('oinniis- sion; e) « greffier » i le registraire de la Com- mission; f) «ministre : le ministre du revenu.Appel 4.1.'appel à la Commission est formé par un avis d'appel qui doit être substantiellement dans la forme exposée à l'annexe « A », adresse au président par lettre recommandée, Il est statué sur l'appel après audition.5.Le greffier doit transmettre une copie de l'avis d'appel au ministre, qui doit alors lui faire parvenir des copies conformes n) de l'avis d'opposition qui lui a été signifié selon l'article 65 de la loi, et b) des avis transmis à l'employeur et au salarié concernée selon l'article 60 de la loi.6.Sur reception des documents transmis par le ministre selon la règle 5, le greffier doit notifier, en leur adressant copie de l'avis d'appel, toutes les autres personnes à qui un avis a été transmis selon l'article 60 de la loi, par lettre recommandée à l'adresse indiquée dans l'avis ou de la manière autorisée par le président.Intervention 7.Une personne qui a reçu une notification selon la règle 6 et qui désire intervenir doit, dans les trente jours de la date de la notification, pro-duire une intervention.8.L'intervention doit être substantiellement dans la forme exposée dans l'annexe « B », ou l'intervenant peut déclarer qu'il a l'intention d'invoquer les moyens contenus dans l'avis d'appel ou dans une autre intervention.9.Lorsque plusieurs personnes à qui des avis ont été transmis par le ministre ont un intérêt commun dans une décision, l'une ou plusieurs d'entre elles, au nom ou en faveur de toutes ces l>ersonncs peuvent a) interjeter appel; /'] intervenir; ou r) être requises ou autorisées par la Commission à produire une intervention.Quebec Pension Boa un Rules of Procedure of the Review Commission Application 1.These rules determine the procedure to be followed on appeals to the Review Commission under section 190 of the Act.2.The Pension Appeals Board is the court which shall act as the Review Commission, pursuant to Order in Council number 911, enacted on May 18, 1966, under section 220 of the Act.Definitions 3.In these rules, the following expressions mean: (a) \"Act\": the Quebec Pension Plan; (b) \"appeal\": (c) \"Board\": the appeal under section 190 of the Act; the Pension Appeals Board; (rf) \"Chairman\": the Chairman of the Pension Appeals Board ; (e) \"Registrar\" : the Registrar of the Pension Appeals Board; (/) \"Minister\": the Minister of Revenue.Appeals 4.An appeal to the Board shall be brought by notice of appeal, which shall be substantially in the form set forth in Schedule \"A\", sent to the Chairman by registered mail.An appeal shall be decided after a hearing.5.The Registrar shall forward a copy of the notice of appeal to the Minister who shall then cause to be transmitted to the Registrar true copies of (a) the notice of objection served on the Minister under section 65 of the Act, and (6) notification sent to the employer and to employee concerned pursuant to section 00 of the Act.6.The Registrar, on receipt of the material transmitted by the Minister pursuant to rule 5.shall notify, by sending a copy of the notice of appeal, all other persons to whom a notification has been sent pursuant to section 66 of the Act.either by registered mail at the address shown on the notification or in such manner as directed by the Chairman.Interventions 7.Any person notified pursuant to rule 0.who desires to intervene, shall, within thirty days from the date of notification, file an intervention.8.An intervention shall be substantially in the form set forth in Schedule \"B\", or an intervener may state that he intends to rely on the grounds set forth in the notice of appeal or in any other intervention.0.Where there are numerous persons to whom notifications have been sent by we Minister, having the same interest in a decision, one or more such persons may (a) appeal, (6) intervene, or (c) be directed or authorized by the Board to file an intervention on behalf of or for the benefit of all such persons. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 17, 1966, Vol.98, No.50 ltepon.se 10.Après l'expiration du délai pour produire l'intervention, le greffier «loit transmettre au ministre COpte conforme «le l'intervention ou l'informer qu'il n'y en a pas eu, et le ministre (loi! alors, «lans les trente joi rs, produire une réponse à l'avis d'appel et à l'intervention, s'il en est, a admettant OU niant les faits allé-gués «lans l'avis d'appel «'t l'intervention, et Ai contenant un énoncé des allégations «le l'ait «-t moyens additionnels sur lesquels il a l'intention de se fonder.M.(l.i Lorsqu'une réponse n'est pas produite ¦ le la manière prévue «lans les présentes règles, lu Commission peut, sur requête
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.