Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 mars 1969, samedi 22 (no 12)
[" 10LU année N° 12 voi- 101 A 1751 T hiette officielle ûu Québec QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE Québec, samedi 22 mars 1969 Règlements 1° Adresser toute correspondance à l'Éditeur ollicicl du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif ollicicl.Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, lu vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat i\\ l'ordre du ministre des Finances.7° Lu Gazelle officielle du Québec est publiée le ¦-¦un .il matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception (les avis, documents ou annonces, expire it midi, le mercredi, u moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur ollicicl du Québec, a le droit de retarder la publication de certains documents, il cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.S° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans nue première insertion, les intéressés sont priés d'eu aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Québec, Saturday, March 22, 1969 Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more tlian once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in ndvancc.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gazelle is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, The Québec Official Publisher, reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Anyrcquestforcancellationorrefundissub-jeet to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Qufbcc, KOCH LEFBBVRB, Quebec Official Publisher 1752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 10V année, n° 12 Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 30 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes pur page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 10 cents la ligne agutc pour chuque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 83 des 100 mots.Exemplaire séparé: 50 cents ehucun.Feuilles volantes: 82 lu douzaine.Abonnement: 810 pnr année ù compter de janvier.N.B.-Les chiffres placés au bus des avis ont lu signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième ù celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Rocn Lefebvhe.Hotel (lu Gouvernement, Québec, 5 mai 1902 Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 30 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 83 per 100 words.Single copies: 50 cents each.Slips: 82 per dozen.Subscriptions: $10 per year from January.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; llic second, that of the edition of the Gaulle carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Rocit Lefebvki:, Québec Official Publisher.Parliament DuildillRS, Quebec, May 5, 1902 27440 \u2014 l-62-e te Ministère des Postes, à Ottawa, a autorisé l'nlTranchisseineut en numéraire et l'envoi comme oltjel de deuxième classe de la présente publication.Authorised as second class mail by tlie Post Omco Department, Ottawa, and for payment of postage in cash.Lettres patentes Letters Patent Adlcr Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 15c jour de janvier 1909, constituant en corporation: David Adler, marchand, Hilda Mazer, ménagère, épouse séparée de biens dudit David Adlcr, tous deux de 80, chemin Hampstead, Hampstead, et Shirley Adler, ménagère, épouse séparée de biens de Ix-slie Cuttlcr, 2280, Mantha, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom de « Adler Development Corp.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 80, chemin Hampstead, Hampstead, district judiciaire de Montréal./-« sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-I'im.iPi'e Bouchard.28400 239-09 Albert's Men's Wear Inc.Mercerie Albert inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de janvier 1909, constituant en corporation : Albert Kofsky, marchand, Denise Kofsky, commis, é|x>usc séparée Adler Development Corp.Notice is given that under Part I of I la-Con! panics Act, letters patent, bearing dute the 15th day of January, 1909, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: David Adler, merchant, Hilda Mazer, housewife, wife separate as to property of I la-said David Adlcr, both of 80 Humpstead Road, Hampstead, and Shirley Adler, housewife, wife separate as to property of Leslie Cuttlcr, 22MI Mantha, Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Adlcr Development Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of the par value of $10 each and 2,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at 80 Hampstead Road, Hampstead, judicial district of Montreal.Ls-PuiLippE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.28400-o 239-00 Albert's Men's Wear Inc.Mercerie Albert inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Albert Kofsky, merchant, Denise Kofsky, clerk, wife separate as to property of the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1909, Vol.101, No.12 de biens dudit Albert Kofsky, tous deux de 4555, lionuvista, Montréal, et Ulric Primcau, retraité, 5300*, Hurling Verdun, pour les objets suivants: Confectionner des vêtements et articles vestimentaires de toutes sortes, en faire le commerce, sous le nom de « Albert's Men's Wear Inc.\u2014 Mercerie Albert inc.», avec un capital total de $-10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1201, est, avenue Mont Royal, Montréal, district judiciaire du .Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400 417-69 American Adventure Tours Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 14c jour de janvier 1969, constituant en corporation: Edward H.Bcrnfeld, Max Bcrnfeld, tous deux avocats et Conseils en Loi de la reine, de 1117 ouest, rue Ste-Catherine, suite 109, Montréal, et Jack B.Bobrove, avocat, 5615, avenue Cork, Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Exploiter une agence de billets et un bureau de voyage dans toutes ses spécialités et agir à titre d'une compagnie de portefeuille, sous le nom de « American Adventure Tours Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Lu siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400 207-69 Ameublements Albert inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24c jour de janvier 1969, constituant en corporation: Thérèse Albert, ménagère, épouse commune en biens de Mathias Brisson et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Alphonse Albert, rentier, tous deux de 22, 17e avenue, Saintc-Marthc-sur-lc-Lac, et Hermine Plouffe, ménagère, veuve de L.-J.-Henri Mcrcillc, 130, St-Laurent, app.1, Saint-Eustache, pour les objets suivants: Faire le commerce de meubles et nouveautés de toutes sortes, sous le nom de « Ameublements Albert inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en_ 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.l.c siège social de la compagnie est 19, rue St-Eustaclie, Saint-Eustache, district judiciaire de Terrebonne.U tous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 297-69 Les Animaux Canadiana inc.Canudiana Livestock Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de décembre 1968, 1753 said Albert Kofsky, both of 4555 Bonavista, Montreal, and Ulric Primcau, retired gentleman, 5800 Burling, Verdun, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Albert's Men's Wear Inc.\u2014 Mercerie Albert inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at 1201 Mount Royal Avenue East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400-o 417-69 American Adventure Tours Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Edward 11.Bcrnfeld, Max Bcrnfeld, both advocates and Queen's Counsels, of 1117 St.Catherine Street West, suite 109, Montreal, and Jack B.Bobrovc, advocate, 5615 Cork Avenue, Cdtc Saint-Luc, for the following purposes: To carry on business as general ticket agency and travel bureau in all its branches and to act as a holding company, under the name of \"American Adventure Tours Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400-o 207-69 Ameublements Albert inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Thérèse Albert, housewife, wife common as to property of Mathias Brisson and duly authorized by him for the presents, Alphonse Albert, annuitant, both of 22, 17th Avenue, Saintc-Marthe-sur-lc-Lac, and Hermine Plouffe, housewife, widow of L.-J.-Henri Mcrcillc, 130 Saint-Laurent, Apt.1, Saint-Eustachc, for the following purposes: To deal in furniture and novelties of all kinds, under the name of \"Ameublements Albert inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 19 Saint-Eustachc street, Saint-Eustachc, judicial district of Terrebonne, Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 297-69 Les Animaux Canadiana inc.Canadianu Livestock Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th (lay of December, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor- 1754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, »° 12 constituant en corporation: Jean Savard, 4351, avenue Draper, Montréal, Raymond Crcvicr, 70, avenue Vivian, Mont-Royal, Louis-Yves Fortier, 40, avenue Arlington, Wcstmount, et Donald Ricndcau, 1750, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce et l'élevage des animaux de ferme et exercer toutes autres opérations reliées à l'agriculture, sous le nom de « Les Animaux Canadiana inc.\u2014 Canadiana Livestock Inc.», avec un capital total de 841,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de la valeur au pair de $1 chacune et en 4,000 actions privilégiées de la valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est a Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 5801-08 E.L.Arbour inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de janvier 1969, constituant en corporation: Elphège Arbour, gérant, Elsie Cécile Marsh, ménagère, épouse dudit Elphège Arbour, et Charles Arbour, gérant, tous trois de Bonaventurc, pour les objets suivants: Exercer'lc commerce de confiseur sous toutes ses formes, sous le nom de « E.L.Arbour inc.», avec un capital total de 860,000, divisé en 600 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Bonaventurc, district judiciaire de Bonaventurc.Le tout-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phii.ippk Bouchard.28400-o 308-69 Armabec inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 5e jour de décembre 1968, constituant en corporation: Maurice Jacques, 1115, Vimont, Claudc-A.Blanchard, 1187, St-Cyrillc ouest, tous deux de Sillery, Charles Cimon, 364,60c rue est, Charlesbourg, Raymond Lessard, Saint-Gabricl-de-Valcartier, Jean Lavoie, 3005, Laroche, app.S, Sainte-Foy, tous cinq avocats, et Jacques Langlois, stagiaire, 3490, Maricourt, app.16, Sainte-Foy, pour les objets suivants: Faire alfaires comme compagnie de transport, sous le nom de « Armabec inc.», avec un capital total de 8200,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune, 18,000 actions privilégiées classe «A » de 810 chacune et en 10,000 actions privilégiées classe « B » de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est i\\ Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 6114-68 Armorex inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la l&\\ des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour de décembre 1968, porating: Jean Savard, 4351 Dra]»er Ave, Montreal, Raymond Crevier, 70 Vivian Ave.' Mount-Royal, Louis-Yves Fortier, 40 Arlington Ave., Westmount, and Donald Riendeau, 1750 Édouard-Laurin Blvd., Saint-Laurent, all four advocates, for the following purposes: To deal in and breed farm animals, and to carry out all operations connected with funning, under the name of \"Les Animaux Canadiuna inc.\u2014 Canadiana Livestock Inc.\", with a total capital stock of $41,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each and 4,000 preferred shares of a par value of $10 each, The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 680148 E.I.Arbour inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 28th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Elphège Arbour, manager, Elsie Cécile Marsh, housewife, wife of said Elphège Arbour, and Charles Arbour, manager, all three of Bonn-venture, for the following purposes: To carry on business as confectioners, under the name of \"E.L.Arbour inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 600 common shares of $100 each.The head office of the company is at Bonnveii-tare, judicial district of Bonaventurc.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 308-09 Armabec inc.Notice is given that under Part I of I lie Companies Act, letters patent, bearing dale the 5th day of December, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Maurice Jacques, 1115 Vimont, Claude-A.Blanchard, 1187 St-Cyrille West, both of Sillery, Charles Cimon, 364, 60th Street East, Charlesbourg, Raymond Lessard, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Jean Lavoic, 3005 Laroche, Apt.8, Sainte-Foy, all five advocates, and Jacques Langlois, probationer, 3490 Maricourt, Apt.16, Sainte-Foy, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Armabec inc.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 10,000 common shares of $1 each, 18,000 preferred class \"A\" shares of $10 each and into 10.1100 preferred class \"B\" shares of $1 each.The head office of the company is at Mon I real, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.28400 6114-08 Armorex inc.Notice is given that under Part I of lia1 Companies Act, letters patent, bearing dale the 17th day of December, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 19G9, Vol.101, No.12 1755 constituant en corporation: André Dessureault, éducateur, 819, boulevard de Maisonncuve est, Germain Pageau, vendeur, 5795, 12e avenue, tons deux de Montréal, et Marcel Paquettc, typographe, 4881, Quévillon, Laval, pour'les objets suivants: Acheter, vendre, assembler, poser et manufacturer tous matériaux et articles employés dans la construction, et particulièrement, des armoires de cuisine et des moulures, sous le nom de « Armorcx inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 390 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 5795, 12c avenue, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 196-69 L'Association des Commerçants de Chicoutimi Centre-Ville inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième parlie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres [latentes, en date du 24e jour de janvier 1969, constituant en corporation sans capital-actions: G.-Bcnoit Ruelland, 94, Jacques-Cartier est, Cicorgcs-Ernest Lessard, 98, Racine est, Jean-Ilaptistc Fraser, 128, Racine est, Michel Thif-fault, 122, Racine est, François Gravel, 44, Racine est, Léo Lessard, 280, Hôtel de Ville, tous six marchands, Marc Savard, 154, Racine est, Joseph Pcdneault, 159, Racine est, tous deux bijoutiers, et Roger Simoncau, gérant, 68, Racine est, tous de Chicoutimi, pour les objets suivants: Protéger et défendre les intérêts économiques, sociaux, professionnels et moraux des membres, sons le nom de « L'Association des Commerçants de Chicoutimi Centre-Ville inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $25,000.Le siège social de la corporation est 94, rue Jacques-Cartier est, Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Le sous-ministre des institutions financières,, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.2S100-o 357-69 Association des Propriétaires et Locataires du Lac Stc-Rosc Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour de janvier 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Paid Rousseau, contremaître de ligne, 363, boulevard Iberville, Robert Daoust, représentant, 60, Place Ruppert, tous deux de Rcpentigny, et Jean Lutteur, directeur d'éducation physique, 595, 27e avenue, app.5, Pointe-aux-Trembles, pour les objets suivants: Promouvoir les intérêts des propriétaires et des locataires, sous le nom de « Association des Propriétaires et Locataires du Lac Ste-Rose».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $100,000.incorporating: André Dessureault, educator, 819 de Maisonneuve Blvd.East, Germain Pageau, salesman, 5795,12th Ave., both of Montreal, and Marcel Paquette, typographer, 4881 Quévillon, Laval, for the following purposes: To buy, sell, assemble, install and manufacture all materials and articles used in construction, and particularly kitchen cupboards and mouldings, under the name of \"Armorox inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a nominal value of $10 each and 390 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at 5795, 12th Ave., Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 196-69 L'Association des Commerçants de Chicoutimi Centre-Ville inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: G.-Benoit Ruelland, 94 Jacques-Cartier East, Georges-Ernest Lessard, 98 Racine East, Jean-Baptiste Fraser, 128 Racine East, Michel Thif-fault, 122 Racine East, François Gravel, 44 Racine East, Léo Lessard, 280 Hôtel de Ville, all six traders, Marc Savard, 154 Racine East, Joseph Pcdneault, 159 Racine East, both jewellers, and Roger Simoneàu, manager, 68 Racine East, all of Chicoutimi, for the following purposes: To protect and uphold the economical, social, professional and moral interests of its members, under the name of \"L'Association des Commerçants de Chicoutimi Centre-Ville inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $25,000.The head office of the corporation is at 94 Jacques-Cartier Street East, Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 357-69 Association des Propriétaires et Locataires du Lac Ste-Rose Notice is given that under Part ni of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Paul Rousseau, line foreman, 363 Iberville Boulevard, Robert Daoust, representative, 60 Place Ruppcrt, both of Repentigny, and Jean Lafleur, director of physical training, 595, 27th Avenue, Apt.5, Pointe-aux-Trembles, for the following purposes: To promote the interests of proprietors and tenants, under the name of \"Association des Propriétaires et Locataires du Lac Ste-Rose\".The amount to which is limited the value of the immovables which may be acquired and owned by the corporation is of $100,000. 1750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, n\" 12 Le siège social de la corporation est à Saint-Damicn, district judiciaire de Jolicttc.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 6062-68 Association sportive des Policiers et Pompiers du Québec inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie- de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 15c jour de janvier 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Marie-A.Pelletier, commerçante, épouse de Hector Sénéchal, 1892, boulevard St-Charlcs, Saint-Charles-de-Lachenaie, Paul Lévcsque, sergent de police, 1919, 53c avenue, et Maurice Lévcsque, pompier, 1240, 15c avenue, ces deux derniers de Pointe-aux-Trembles, pour les objets suivants: Promouvoir l'esprit sportif chez les policiers et les pompiers de la province de Québec, sous le nom de « Association sportive des Policiers et Pompiers du Québec inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $10,000.Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 5692-68 Astro construction inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour de janvier 1969, constituant en corporation: Picrre-L.I.a pointe, 155, Marcotte, Saint-Laurent, Michel Saint-Aubin, 531, Davaar, Outremont, et Jacqucs-Lcmat-tre Auger, 8462, Drolct, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de * Astro construction inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 20,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 7521, Roi René, Anjou, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 442-69 Atelier IxiisirH-Danscs Victo inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de janvier 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Jos.Hamel, technicien, Rita St-Cyr, ménagère, épouse dudit Jos.Hamel, tous deux de 58, Pcrreault, et Pierre Hamel, coiffeur, 6, rue Pigeon, app.2, tous trois de Victoriaville, pour les objets suivants: Établir et exploiter un club social, sous le nom de « Atelier Loisirs-Danses Victo inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut ucquérir et posséder, est tie $40,000.The head office of the corporation is at Saint-Damicn, judicial district of Joliette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 6002-68 Association sportive des Policiers et Pompiers du Québec inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent bearing dale the 15th day of January, 1969, have been issued hy the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Marie-A.Pelletier, trader, wife of Hector Sénéchal, 1892 Saint-Charles Boulevard, Saint.Charlcs-dc-Lachcnaic, Paul Lévesque, policeman, 1919, 53rd Avenue, and Maurice Lévcsque, lire-man, 1240, lôth Avenue, the latter two of Pointeaux-Trembles, for the following purposes: To promote sportsmanship among policemen and firemen in the Province of Québec, under the name of \"Association sportive des Policiers et Pompiers du Québec inc.\".The amount to which arc limited the immovables which may be acquired and owned hy the corporation is of $10,000.The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ire».28400 5692-OS Astro construction inc.Notice is given that under Part I of I he Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre-L.Lapointe, 155 Marcotte, Saint-Laurent, Michel Saint-Aubin, 531 Davaar.Outrcmont, and Jacques-Lemattre Auger, MG2 Drolct, Montreal, all three advocates, for I In-following purposes: To carry on business us builders and general building contractors, and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Astro construction inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 7521 Roi René, Anjou, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Inst Hut ions.Companies and Cooperative*.28400 442 ti'.» Atelier Loisirs-Danses Vie-to inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing (laic the 22nd day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, to incorporate a corporation without share capital: Jos.Hamel, technician, Rita St-Cyr, housewife, wife of the said Jos.Hamel, both of 58 Perreault, and Pierre Hamel, hairdresser, 6 Pigeon Street, Apt.2, all three of Victoriaville, for the following purposes: To establish and operate a social club, under the name of \"Atelier Loisirs-Danses Victo inc.\".The amount to which arc limited the immovables which may be acquired and owned by the corporation is of $40,000. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, J9G9, Vol.101, No.12 Le siège social de la corporation est à Victoria-ville, district judiciaire d'Ârthabaska.le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.2S400-o 174-69 Autodromc Drummond inc.Avis est donné qu'en vertu de la première parlic de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de janvier 1969, constituant en corporation: Marshall Grenick, gérant, 107, Rajotte, Jacques Côté, restaurateur, 524, rue St-Georges, Nicol Lacroix, employé d'usine, rue Cardin, Serge Dionne, 443a, Cock-Inirn, tous quatre de Drummondville, et Gilles Lacroix, 800, boulevard Foucault, Drummond-ville-Nord, ces deux derniers commerçants, pour les objets suivants: Exploiter commercialement un hippodrome, sous le nom de « Autodrome Drummond inc.», avec un capital total de 8200,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 10,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Majorique, district judiciaire de Drummond.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 344-69 B.T.R.Cosmétiques inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour de janvier 1969, constituant en corporation: Maurice Beaudoin, S3, boulevard des Hauteurs, Lafontaine, Réal Tremblay, 253, Croissant Dubois, Chûteauguay-Ccntre, et A.-Rosairc Rochon, 382, Rochon, Saint-Jérôme, tous trois distributeurs, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de cosmétiques, lotions, parfums, savons, produits à base naturelle et autres produits semblables, sous le nom de « B.T.R.Cosmétiques inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,500 actions ordinaires de 810 chacune et en 150 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est 1600, rue llerri, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.-N400-o 434-69 Beaudoin transport Itéc Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour de septembre 1968, constituant en corporation: Georges Bouchard, administrateur, Véronique Larouche, commerçante, épouse séparée de biens dudit Georges Bouchard, tous deux de 1606, rue Couvrette, Saint-Laurent, Irenéc LeBel, gérant, 1955, rue < harland, Montréal, et Maurice Bouchard, comp-I able général agréé, 124, 41c rue, Saint-Georges, comté de Beaucc, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de transport, sous le nom de « Beaudoin transport ltéc », avec mi capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.1757 The.head office of the corporation is at Victoria-ville, judicial district of Arthabaska.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 174-69 Autodrome Drummond inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Marshall Grenick, manager, 107 Rajotte, Jacques Côté, restaurant keeper, 524 St-Georges Street, Nicol Lacroix, factory worker, Cardin Street, Serge Dionne, 443a Cockburn, all four of Drummondville, and Gilles Lacroix, 800 Foucault Boulevard, Drummondville-North, the latter two traders, for the following purposes: To commercially operate a hippodrome, under the name of \"Autodrome Drummond inc.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 10,000 common shares of $10 each and into 10,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Saint-Majorique, judicial district of Drummond.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Inslihitions, Companies and Cooperatives.28400 344-69 B.T.R.Cosmétiques inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Maurice Beaudoin, 83 des Hauteurs Boulevard, Lafontaine, Réal Tremblay, 253 Croissant Dubois, Chuteauguay-Centrc, and A.-Rosaire Rochon, 382 Rochon, Saint-Jérôme, all three distributors, for the following purposes: To manufacture and deal in cosmetics, lotions, perfumes, soaps, natural foundation products and other similar products, under the name of \"B.T.R.Cosmétiques inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,500 common shares of $10 each and into 150 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 1600 Berri Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 434-69 Beaudoin transport ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of September, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Georges Bouchard, administrator, Véronique Larouche, trader, wife separate as to property of said Georges Bouchard, both of 1606 Couvrettc street, Saint-Laurent, Irenée LeBel, manager, 1955 Charland Street, Montreal, and Maurice Bouchard, general chartered accountant, 124,41st Street, Saint-Georges, county of Beaucc, for the following purposes: To carry on business as a transportation company, under the name of \"Beaudoin transport ltée», with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of 810 each. 1758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, n° 12 Le siège social de la compagnie est 1606, rue Couvrettc, Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 428-69 lirantcr inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour de janvier 1969, constituant en corporation: Gérard Beauregard, Paul N.Bruhmuller, et Michael Russcl Murphy, tous trois administrateurs, de Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes d'accessoires pour fins domestiques ou commerciales, sous le nom de « Beauger inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune et en 20,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Victoria-ville, district judiciaire d'Arthabaska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives,.Ls-Philippe Bouchard.28400-o 467-69 Beauté Boutique inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22c jour de janvier 1969, constituant en corporation: Pierre Villa, ingénieur, 2570, des Hospitalières, Sillcry, Fcrnand Gil, représentant, 370, Fraser, Québec, et Raymond Sterna, directeur commercial, 2300, St-Mathieu, app.411, Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce du savon et de ses produits, parfums, cosmétiques, lotions et autres produits semblables, sous le nom de « Beauté Boutique inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 300 acions ordinaires de $100 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 2570, des Hospitalières, Sillcry, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutionsfi7iancières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 348-69 Bersol Distributors Inc.Distributeurs Bersol inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de janvier 1969, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat et conseil en Loi de la reine, 5654, avenue Macdonald, Hampstead, Jason Ruby, 47, place du Bois, Dollard-dcs-Ormeaux, John Michelin, 5754, rue Lockwood, tous deux avocats, et Glacia Miller, secrétaire, célibataire, 3201, avenue Forest Hill, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer des marchandises, articles et effets de toutes sortes et descriptions, en faire le commerce, sous le nom de « Bersol Distributors Inc.\u2014 Distributeurs Bersol inc.», avec un capital The head office of the company is at 1000 Couvrette Street, Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 428-69 Bcaugcr inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 31st day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gérard Beauregard, Paul X.Bruhmuller and Michael Russcl Murphy, all three administrators of Sherbrooke, for I he following purposes: To deal in all kinds of accessories for domestic or commercial purposes, under the name of \"Bcaugcr inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of a nominal value of $1 each and into 20,000 preferred shares of a nominal value of $1 each.The head office of the company is at Victoria-ville, judicial district of Arthabaska.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 467-69 Beauté Boutique inc.Notice is given that under Part I of Ihe Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Villa, engineer, 2570 des Hospitalières, Sillery, Fernand Gil, representative, 370 Fraser, Québec, and Raymond Sterna, commercial director, 2300 St-Mathicu, Apt.411, Montreal, for the following purposes: To carry on business dealing in soap and its products, perfumes, cosmetics, lotions and other similar products, under the name of \"Beauté Boutique inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of 8100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 2570 des Hospitalières, Sillery, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 3484» Bersol Distributors Inc.Distributeurs Bersol inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Louis Orenstein, advocate and Queen's Counsel, 5654 Macdonald Avenue.Hampstead, Jason Ruby, 47 Place «lu Bois, Dollard-des-Ormcaux, John Michelin, 5754 Loci wood Street, both advocates, and Glacia Mille secretary, spinster, 3201 Forest Hill Avenue, the latter two of Montreal, for the following purposes To manufacture and deal in goods, wares and merchandise of every kind and description, under the name of \"Bersol Distributors Inc.\u2014 Distributeurs Bersol inc.\", with a total capital stock »! QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 total our les objets suivants: Exploiter un hôtel, taverne, discothèciuc, club de nuit, auberge, bars, restaurants et/ou établissements semblables, sous le nom de « Friday's Ltd.», avec un capital-actions divisé en 20,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 2,000 actions privih'-giées d'une valeur au pair de 810 chacune.Federation des Clubs de Montagne du Québec inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd ilay of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, to incorporate a corporation without share capital: Claude Lavallée, policeman, 167 Place Champlain, Saint-Bruno-dc-Montarville, Gilles Parent, professor, 1260 Louvain St.East, and Michel-H.Gosselin, chartered accountant, 3864 Pare Lafontainc, the latter two of Montreal, for the following purposes: To promote sports und physical education in general, nnd, in particular, mountain sports and mountain safety, under the name of \"Fédération des Clubs de Montagne «lu Québec inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is 810,000.The heail office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 359-69 Friday's Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Harold Philip Gordon, 414 Wood Avenue, Westmount, Stanley Herbert Hartt, 5526 Ashdalc.Côte Saint-Luc, both advocates, Margot Mary Quinn, 5940 Monkland, and Marie Nassa, 6653 Louis Hémon, the latter two secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of hotel, tavern, discotheque, night club, public house, bars, restaurants and/or similar establishments, under the name of \"Friday's Ltd.\", with a capital stock divided into 20,000 common shares without par value and 2,000 preferred shares of the pur value of 810 each. 1772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 mars 1969, 101' année, n° 12 Le siège social «le la compagnie est 1255, carré Phillips, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Kouciiard.28400 536-69 Fiiscliino & associés inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 8c jour de janvier 1969, constituant en corporation: Bruno lté muni, avocat, 3408, Carré Roland, Denise Gravel, secrétaire, épouse de Jean-Pierre Gravel, 3471, Clérin, tous deux de Sainte-Foy, et Louise Lessard, secrétaire, épouse de Jacques Girard, 543, Route Nationale, Saint-Augustin-dc-Dcsmaures, pour les objets suivants: Agir comme consultant et aviseur auprès de toutes entreprises publiques ou privées, sous le nom de < Fuschino & associés inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et en 1,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la rompagnie est 59, rue Fraser, Lévis, district judiciaire «le Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 152-69 Garceuu et Lefebvro inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour «le février 1969, constituant en corporation: Maurice Garceau, commerçant, Rita Boucher, ménagère, épouse conlractucllement séparée de biens dudit Maurice Garceau, Paul Lefebvrc, commerçant, et Violette Lamontagne, ménagère, épouse contrnctuel-lement séparée de biens dudit Paul Lefebvrc, tous quatre de Saint-Amhroise-dc-Kildare, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, autos-neige, motocyclettes, remorques, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « Garceau et Lefebvrc inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «le $10 chacune et en 300 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Ambroisc-tlc-Kildare, district judiciaire de Joliettc.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 5791-68 Gémico ltée Avis est donné quYii vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de décembre 1968, constituant en corporation: Ruth De Kintler, secrétaire, épouse séparée «le biens «le Louis De Kinder, 10184, Marquette, Jean-Marc Pou-lin, avocat, 11765, Alexandre-Lacoste, tous deux de Montréal, et Pierrette Boilie, secrétaire, épouse «le Jean-Marc Boilie, 9178, 12c avenue, Saint-Michel, pour les objets suivants: The head office of the company is at 1255 Phillips Square, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400-o 536-69 Fuschino & associés inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Bruno Bernard, advocate, 340S Carré Roland, Denise Gravel, secretary, wife of Jean-Pierre Gravel, 3471 Clérin, both of Sainte-Foy, and Louise Lessard, secretary, wife of Jacques Girard, 543 National Route, Saint-August in-dc-Desmaurcs, for the following purposes: To act as consultants and advisors to public or private enterprises, under the name of \"Fuschino & associés inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 250 common shares of $100 each and into 1,500 preferred shares of SKI each.The head office of the company is at 59 Fnucr Street, Levis, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 152-119 Garceau ot Lcfchvrc inc.Notice is given that under Part I of I lie Companies Act, letters patent, liearing date the 4th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province incorporating: Maurice Garceau, trader, Rita Boucher, housewife, wife contractually separate as to property of said Maurice Garceau, Paul Lefebvre, trader, and Violette Lamontagne.housewife, wife contractually separate as In property of said Paul Lefebvre, all four of Saint-Ambroise-de-Kildarc, for the following purposes: 'lo carry on business as gnrage-kec|k-rs ami to deal in automobiles, motors, snowmobiles, trailers, machines and all their accessories and parts, under the name of \"Garceau et Lefebvre inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Saint-Ambroisc-dc-Kildarc, judicial district of Joliclle.Ls-Philippe Bouchakii, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 5701-OS ( .cm ii n ltée Notice is given that under Part I of lite Companies Act, letters patent, bearing dale the 30th day of December, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Ruth Dc Kinder, secretary, wife separate as to property of Louis De Kinder, 10184 Marquette, Jean-Marc Poulin, advocate 11765 Alexandre-Lacoste, both of Montreal, and Pierrette Boilie, secretary, wife of Jean-Marc Boilie, 9178, 12th Ave., Saint-Michel, for (lie following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 19G9, Vol.101, No.12 1773 Paire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom «le « Gémico ltée >, avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 30,000 actions privilégiées «le $.1 chacune.I.c siège social de la compagnie est ù Montréal, district judiciaire de Montréal.l.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopêratires, Ls-PlIIMPFE bouchard.2S400-o 4-09 Giligon inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour de janvier 1969, constituant en corporation: Gilbert Gonthier, industriel, Barraute, Maurice Martel, avocat et conseil en Loi de la reine, 1301, St-Viateur ouest, Outrcinont, et Lucille Roy, secrétaire, épouse de Jean-Claude Biais, 24, rue Gilles, Saintc-Thèrèsc-Ouest, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille, de placement et de gestion, sous le nom de « (îiligon inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 40 actions ordinaires de Si chacune, 3,992 nctions privilégiées classe «A» de 810 chacune et en 40 nctions privilégiées classe « B » de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Barraute, district judiciaire d'Abitibi./.c .mus-ministre des institutions financières, compagnies et coopêratires, Ls-Philippe Bouchard.2S400-o 309-69 Gingras & Gingras limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de janvier 1969, constituant en corporation: Guy Gingras, 8751, Ile avenue, René Gingras, 9155, 15e avenue, f4, tous deux techniciens, et Claude Durocher, comptable, 8020, de Lourcsse, tous trois de Montréal, jxnir les objets suivants: Faire le commerce et la réparation de toutes sortes d'appareils ou systèmes de chauffage, automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « Gingras Si (iingras limitée», avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions ordinaires de S100 chacune et en 100 actions privilégiées «le 8100 chacune.Le siège social de-la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.U sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopêratires, Ls-Philippe Bovchakd.\"-MOO-o 429-69 Georges Hamel inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de janvier 1969, \"instituant en corporation : Georges Hamel, hriqueteur, Jeannette Doucct, ménagère, épouse dudit Georges Hamel, tous deux de route rurale numéro 3, et Alphonse Hamel, briqueteur, 80, 15c avenue, tous trois de Drummondville, pour les objets suivants: To carry on business as builders and general building contractors, and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Gémico ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and 30,000 preferred shares of 81 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 4-69 Giligon inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilbert Gonthier, industrialist, Barraute, Maurice Martel, advocate and Queen's Counsel learned in the law, 1301 St-Viateur West, Outremont, and Lucille Roy, secretary, wife of Jean-Claude Biais, 24 Gilles Street, Saintc-Thérèsc-Wcst, for the following purposes: To carry on business as a holding, investment and management company, under the name of \"Giligon inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 40 common shares of 81 each, 3,992 preferred class \"A\" shares of 810 each and into 40 preferred class \"B\" shares of 81 each.The head office of the company is at Barraute, judicial district of Abitibi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 309-69 Gingras & Gingras limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Guy Gingras, 8751, 14th Avenue, René Gingras, 9155, 15lh Avenue, #4, both technicians, and Claude Durocher, accountant, 8620 de Louresse, all three of Montreal, for the following purposes: To deal in and repair all kinds of beating appliances or systems, automobiles, motors, machines ami all their accessories and parts, under the name of \"(iingras & Gingras limitée\", with a total capital stock of S40.000, divided into 300 common shares of 8100 each and into 100 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Montrael, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopcratires.28400 429-69 Georges Hamel inc.Notice is given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1969, have been issued hy the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Georges Hamel, bricklayer.Jeannette Doucet, housewife, wife of said Georges Hamel, both of Rural Route number 3, ami Alphonse Hamel, bricklayer, 80, 15th Avenue, all three of Druininondvillc, for the following purposes: 1774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, n° 12 Faire affaires comme entrepreneurs briquc-teurs, sous le nom de « Georges Hamel inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune, 380 actions privilégiées classe « A » de $100 chacune et en 100 actions privilégiées classe « B » de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Drum mondivlle, district judiciaire de Drummond.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopêralives, Ls-Philippe Bouchahd.28400-o 332-69 Harmonie de Coaticook Coaticook Harmony Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 15c jour de janvier 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Gilles Lapointe, commerçant, 320, rue St-Edmond, Martial Martincau, journalier, 144, rue Vcrrette, et John Sharpe fils, contremaître, 127, rue St-Jacqucs sud, tous trois de Coaticook, pour les objets suivants: Promouvoir l'art musical, sous le nom de « Harmonie de Coaticook \u2014 Coaticook Harmony ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $100,000.Le siège social de la corporation est à Coaticook, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 171-69 Les Hélicoptères Trans-Québcc limitée Truns-Québcc Helicopters Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de fcvricrl969, constituant en corporation: Antonio Simard, industriel, 652, lrc rue ouest, André Simard, hôtelier, 652, 4e rue est, tous deux d'Amos, et Jacques Labarrc, administrateur, 1160, de l'Assomption, Laval, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de vaisseaux aériens de toutes sortes, moteurs, bateaux, instruments de navigation aérienne, appareils et accessoires, sous le nom de « Les Hélicoptères Trans-Québec limitée\u2014Trans-Québcc Helicopters Limited », avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 20,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Amos, district judiciaire d'Abitibi.Lt sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopêralives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 817-09 Lit.S.Industrial Bearing & Supplies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de janvier 1969, constituant en corporation: Fcrnand Larocquc, industriel, 1042, 5e rue, Guy Rochon, commerçant, et Shirley Rochon, ménagère, épouse sépn- To carry on business as bricklaying contractors' under the name of \"Georges Hamel inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each, 380 preferred class \"A\" shares of $100 each and into 100 preferred class \"B\" shares of $10 each.The head office of the company is al Drum-mondvillc, judicial district of Drummond.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 332-0!) Harmonic dc Coaticook Coaticook Harmony Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, to incorporate a cor|>oration without share capital: Gilles Lapointe, trader, 320 St-Edmond St., Martial Martincau, labourer, 144 Vcrretle, and John Sharpe, Jr., foreman, 127 St-Jacqucs St.South, all three of Coaticook, for the following purposes: To promote the art of music, under the name of \"Harmonic de Coaticook \u2014 Coaticook Harmony\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is limited, is $100,000.The head office of the corporation is at Coaticook, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 171-011 Les Hélicoptères Trans-Québcc limitée Trans-Québcc Helicopters Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of February, 1969, have been issued hy the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Antonio Simard, industrialist, 652, 1st Street West, André Simard, innkeeper, 652,41 li Street East, both of Amos, and Jacques Labarrc, administrator, 1160 de l'Assomption, Laval, for the following purposes: To manufacture and ileal in aircraft of all kinds, motors, boats, aerial navigation instruments, appliances and accessories, under the name of \"Les Hélicoptères Trans-Quebec limitée \u2014 TransQuébec Helicopters Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20.000 common shares of $1 each and into 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Amos, judicial district of Abitibi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 SI 7-00 I.B.S.Industrial Bcuring & Supplies Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Fcrnand Larocque, industrialist, 101'-', 5th Street, Guy Rochon, trader, and Shirley Rochon, housewife, wife separate as to property QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1909, Vol.101, No.12 réc de biens dudit Guy Rochon, ces deux derniers «le 341, lie rue, tous trois de Val d'Or, pour les objets suivants: Faire le commerce de courroies, boyaux, roulements à billes industriels et généralement de pièces pour la machinerie lourde, sous le nom de « I.B.S.Industrial Bearing & Supplies Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 321-69 ICM ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1969, constituant en corporation: Michel Robert, avocat, 782, Wiseman, Outremont, Lucien Danse-rcau, avocat, 4977, Jean-Brillant, Marcelle Cour-noyer, 5170, lie avenue, app.3, et Denyse Bergeron, 1735, Henri-Bourassa est, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, ces trois derniers de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en plomberie, chauffage et en réfrigération, sous le nom de « ICM ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 390 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 3500, Parc La ïon lai ne, suite 210, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchahd.2S400-o 126-69 Les Immeubles JRM inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de janvier 1969, constituant en corporation : Jean-Claude Gagnon, 50, boulevard Arthur Buics, Paul-Emile Gagnon, 51, rue St-Jcaii, tous deux avocats, et Claudette Lauzier, secrétaire, fille majeure, 314, du Rosaire, tous trois de Rimouski, pour les objets suivants: l'aire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Les Immeubles JRM inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopêralives, Ls-Philippe Bouchard.28400-o 5983-6S Les Immeubles Riverains ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1969, constituant en corporation: Georges-A.Daiglc, G, Mont-Marie, Gérald Corriveau, 168, St-Georges, tous deux médecins, de Levis, et Fernand Darveau, constructeur, 1143, Beaupré, Sainte-Foy, pour les objets suivants: 1775 of said Guy Rochon, the latter two of 341,11th Street, all three of Val d'Or, for the following purposes: To deal in straps, hoses, industrial ball-bearings and in heavy machinery generally, under the name of \"I.B.S.Industrial Bearing & Supplies Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 321-69 ICM ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Michel Robert, advocate, 782 Wiseman, Outremont, Lucien Dansereau, advocate, 4977 Jean-Brillant, Marcelle Cournoyer, 5170, 11th Avenue, Apt.3, and Dcnysc Bergeron, 1735 Henri-Bourassa East, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, the latter three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as plumbing, heating and refrigeration contractors, under the name of \"ICM ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of SI each and into 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 3500 Lafontaine Park, suite 210, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.2S400 126-69 Les Immeubles I KM inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Claude Gagnon, 50 Arthur Buies Blvd., Paul-Emile Gagnon, 81 St-.Tean St., both advocates, and Claudette Lauzier, secretary, spinster of the full age of majority, 314 du Rosaire, all three of Rimouski, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Les Immeubles JRM inc.\", with a total capital stock of 540,000, divided into 200 common shares of a nominal value of $100 each and 200 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Rimouski, judicial district of Rimouski.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 59S3-69 Les Immeubles Riverains ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Georges-A.Daiglc, 6 Mont-Marie, Gérald Corriveau, 168 St-Georges, both'doctors of Levis, and Fernand Darveau, constructor, 1143 Beaupré, Sainte-Foy, for the following purposes: 1776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 mars i960, 101' année, n° 12 Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Les Immeubles Riverains ltée», avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 6, Mont-Marie, Lévis, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.2S400-o 129-69 J.L.inc.Avis est donné qu'en vertu de la premier»' partir de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de janvier 1969.constituant en corporation: Claude Lefebvrc, 600, Fontainebleau, Jean-Claude Mercure, 697, Autcuil, tous deux de Laval, et Jacques Mochon, 9129, Louisannc, Saint-Léonard, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « J.L.inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sainte-Thérèse, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28400m 423-59 Jul Oruugc Julcp Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province n accordé des lettres patentes, en date du 30c jour de décembre 1908, constituant en corporation: (îuy-Frédéric Gcr-vais, 1195, Qucnneville, André Valiquette, 3340, Beauséjour, tous deux avocats, de Saint-Laurent, et Micheline Pilotte, secrétaire, épouse séparée de biens de Réal Bercier, 4295, Hochelaga, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Jul Orange Julcp Inc.», avec un capital total île $40,000.divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune, 38,000 actions privilégiées classe « A» de $1 chacune et en 1,000 actions privilégiées classe « B » de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 5889, liou-levard Gouin ouest, Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopêratires, Ls-Philippe Bouchard.2S400-o 216-69 Kebec Truck Center (1969) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partir de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 14c jour «le janvier 1969, constituant en corporation: Daniel Kingstonc, 4985, loua, Montréal, Dionysia Zerbisias, célibataire, 5525, Wcstbournc, Côte Saint-Luc, et Gilles Poulin, 1270, Qucnneville, Saint-Laurent, tons trois avocats, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de garagistes et faire le commerce «le toutes sortes d'automobiles, moteurs, engins, machines, carburateurs, accessoires et pièces, sous le nom de « Kebec Truck To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Leg Immeubles Riverains ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each and into 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 6 Mont-Marie, Levis, judicial district of Quél>cc.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 120-00 J.L.inc.Notice is given that untler Part 1 of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Claude Lefebvre, 600 Fontainebleau, Jean-Claude Mercure, 697 Autcuil, both of Laval, and Jacques Mochon, 9129 Louisannc, Saint-Léonard, all three advocates, for the follow ing purposes: To carry on business as builders uud general building contractors, and to ileal in all kinds of materials, under the name of \"J.L.inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Sainte Thérèse, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopcratires.28400 423-69 Jul Orange Julep Inc.Notice is given that under Part I of tile Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of December, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Guy-Frédéric Gcrvais, 1195 Qucnneville, André Valiquette, 3340 Beauséjour, both advocates, of Saint-Laurent, and Micheline Pilotte, secretary, wife separate as to property of Réal Bercicr, 4295 Hochelaga, Montréal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Jul Orange Julep Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $10 each, 38,000 class \"A\" prefcrreil shares of $1 each and 1,000 class \"II\" preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 6880 Gouin Boulevard West, Saint-Laurent, judicial district of Montreal.I.-l'mi.iiTi: Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Coopcratires.28400 216-69 Kebec Truck Center (1969) Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 14th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Daniel Kingstonc, 49S5 Ionn, Montreal, Dionysia Zerbisias, spinster, 5525 West-bourne.Côte Saint-Luc, and Gilles Poulin, 1270 Qucnneville, Saint-Laurent, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers and to ileal in all kinds of automobiles, motors, engines, machines, carburetors, accessories and parts, under the name of \"KcIh-c Truck ('enter QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1909, Vol.101, No.12 1777 Center (1969) Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.I .r siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopêratires, Ls-Philippe Bouchard.28400 203-69 L.F.construction inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres liatcntcs, en date du 21e jour de janvier 1969, constituant en corporation: Émilicn Vallée, avocat.500, Place d'Armes, cliamlirc 1155, Maricl Desmartcau, 4522, Duqucsne, tous deux de Montréal, et Muriellc Gagné, 2220 Oslo, Laval, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, |>our les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « L.F.construction inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune.\\œ siège social de la compagnie est 6830, 6e avenue, Montréal, district judiciaire de Montréal.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopêralives, Ls-Philippe Bouchard.2S400-o 318-69 I.anion inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de In Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres liatcntcs, en date du 14e jour de janvier 1969, constituant en corporation: Gaston Proulx, comptable! 305, des Bouleaux ouest, Doris llavard, comptable, fille majeure, 75, Stc-Annc, cl Bernadette Fontaine, secrétaire, fille majeure, 617, 4c avenue, tous trois île Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction, de placement et de portefeuille (holding), sous le nom de < I.anion inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune.I.e siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopêratires, Ls-Philippe Bouchard.2S400-o 211-69 JucqucM I ai in Entreprises inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour de janvier 1969, constituant en corporation: Jacques Larin, 6705, l'aul-Emilc Lamnrchc, Saint-Léonard, Ré Jean Bonami, 2381, Iberville, et André Trudel, 2181 A, Dczery, ces deux derniers de Montréal, tous trois hommes d'affaires, pour les objets suivants: Faire le commerce de tous produil-, articles et marchandises et exploiter une agence «le théâtre, sous le nom de « Jacques Larin Entreprises inc., avec un capital total de $40.000.divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune cl en 300 actions privilégiées de $100 chacune.(1969) Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies arid Cooperatives.28400-o 203-69 L.F.construction inc.Notice is given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Émilien Vallée, advocate, 500 Place d'Armes, Suite 1155, Maricl Desmartcau, 4522 Duqucsne, both of Montreal, and Muriellc Gagné, 2220 Oslo, Laval, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, for the following purposes: To carry on business as constructors and general building contractors and to deal in all kinds of materials, under the name of \"L.F.construction inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at 6S30, 6th Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28400 318-09 Lan ton inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gaston Proulx, uccountaut, 305 des Bouleaux West, Doris Ilavard, accountant, spinster of the full age of majority, 75 Stc-Anne St., and Bernadette Fontaine, secretary, spinster of the full age of majority, 617, 4th Ave, all three of Quebec, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construe tion, investment and holding company, under the name of \"1.anion inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Lfi-PllIi.ippi; Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Com punies and Cooperatives.28400 211-69 Jacques I aiin Entreprises inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacques Larin, 6705 Paul-Emile La-marche, Saint-Léonard, Réjean Bonami, 2381 Iberville, and André Trudel, 2181 A, Dczery, the latter two of Montreal, all three businessmen, for the following pur|x>ses: To deal in all products, articles and merchandise anil to operate a theatrical agency, under the name of \"Jacques Larin Entreprises inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shurcsjof $100 each and 300 preferred shares of $100 each. 1778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, n\" 12 _ Le siège social ar une partie dudit lot trois (3) A, appartenant à W.H.R.Denman et une partie par une autre partie dudit lot numéro trois (3) A appartenant à Aldéric Brièrc et de l'autre côté par le numéro quatre (4) A.Superficie: sept mille neuf cent cinquante-trois (7,953) acres.Un autre lopin de terre dc forme irrégulière situé au même lieu, mesurant quatrc-vingkdix-neuf (99) pieds de largeur en front le long du chemin public, quatre-vingt-cinq (85) en arrière le long du Lac St-Joseph, trente-sept (37) dans sa ligne sud-est et trente-neuf (39) dans sa ligne nord-ouest, contenant une superficie de trois mille trois cent quatre-vingt-trois (3,383) pieds carrés, connu et désigné comme faisant partie du lot numéro trois (3) À du sixième rang du canton Howard des plans et livre de renvoi officiels.Taxes scolaires et frais: $473.66; taxes municipales et frais: $227.35.Total: $701.01.Placements Altitude 1500 Investments Inc., 0620, 26e Avenue, Rosemont, Québec.\u2014 Lot 5A, subdivision 14.Lot connu et désigné sous le numéro quatorze (14) de la subdivision officielle du lot originaire numéro cinq (5) A dans le sixième rang du canton Howard, au plan et livre dc renvoi officiel dudit canton dans le comté d'Argenteuil.Taxes scolaires et frais: $41.14.Serge Paquin, adresse inconnue.\u2014 Lot 9-11.Un emplacement connu et désigné comme étant le lot numéro onze (11) de la subdivision officielle du lot originaire numéro neuf (9) dans le septième rang, canton Howard nu plan et livre île renvoi officiel dudit canton dans le comté Argenteuil.Such as the whole is presently found with all servitudes, active and passive, apparent or occult, attached to the said emplacement; With a summer camp to be constructed thereon by the vendor, and with a right of way with all others allowed, on the planned streets communicating to the said emplacement, to the lake and beach, but the vendor will not be held responsible for any damages following the accidents which may occur on the said lands.Municipal taxes: $30.00; interest and costs: $2.05; school taxes 1967-1968: $24.98; interest and costs: $3.21; school taxes 1968-1969: provisional: $22.50; interest and costs: 81.97.Total: $84.71.The corporation of Saint-AdoIphc-d'Howanl Kurt Angcrman, address unknown.\u2014 Lot 14-88 range III.Subdivision eighty-eight (88 of original lot fourteen (14) range III of the official plan and book of reference of the township of Howard, on the south of lac i\\ la Truite.Area eleven thousand fifty-two (11,052) square feel.School taxes and costs: $120.01; municipal taxes and costs: $79.31.Total: $199.32.Robert Banncrman, 49.15th Avenue.Calumet.\u2014 Lot 20-11 range IV.Subdivision eleven (11) of original lot twenty (20) range IV on the official plan and book of reference of the township of Howard.Area seventeen thousand nine hundred (17,900) squnrc feet.' School taxes and costs: $88.08; municipal taxes and costs: $22.00.Total: 8110.08.Albert Edward Stairway, address unknown.-Lot 3A, range VI.Part three (3) A of the sixth range of the township of Howard and bounded in front on the northeast by the public road, in the back on the southwest by a part of lot number three (3) A, belonging to Aldéric brièrc on one side, on the southeast by a pari of said lot three (3) A, belonging to W.H.R.Dcmnan and a part by another part of said lot number three (3) A belonging to Aldéric Brièrc and on the other side by number four (4) A.Area: seven thousand nine hundred and fifty-three (7.953) acres.Another strip of land of an irregular form situated at the same place, measuring ninety-nine (99) feet in width in front along the public road, eighty-five (85) in rear along Snint-Ioseph Lake, thirty-seven (37) on its southeast and thirty-nine (39) on its northwest line, containing an area of three thousand three hundred and eighty-three (3.383) square feet, known and designated as being part of lot number three (3) A of the sixth range of the township of Howard, on the ollicial plan and book of reference.School taxes and costs: 8473.66; municipal taxes and co-Is: $227.35.Total: $701.01.Placements Altitude 1500 Investments Inc., 6620.20th Avenue, Rosemont, Québec\u2014 Lot 5A, subdivision 14.A lot known and designated under number fourteen (14) of the official subdivision of original lot number five (5) A in the sixth range of the township of Howard, on the ollicial plan and book of reference of the said township in the county of Argenteuil.School taxes and costs: $41.14.Serge Paquin, address unknown.ImI 9-11.An emplacement known and designated as being lot number eleven (11) of the official subdivision of original lot number nine (9) in the seventh range, township of Howard, on the ollicial plan and book of reference of the said township QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1811 Taxes scolaires et frais: $13.50; taxes municipales et frais: $9.81.Total: $23.31.Jacques Clermont, 5529,3e Avenue, Rosemont, Québec.- Lots 8-239, 7-206 à 209.Lot connu et désigné sous le lot 239 de la subdivision officielle du lot originaire numéro huit (8) dans le sixième rang, canton Howard, et sous les lots numéros 206, 207, 208 et 209 de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept (7) dans le sixième rang, canton Howard au plan et livre de renvoi ollicicl dudit canton dans le comté d'Argenteuil.Taxes scolaires et frais: $16.84.William Nelson, adresse inconnue.\u2014 Lot 10-110.Un emplacement connu et désigné sous le lot cent seize (110) de la subdivision officielle du lot originaire numéro dix (10) dans le sixième rang canton Howard, au plan et livre de renvoi officiels dudit canton dans le comté Argenteuil.Taxes scolaires et frais: $18.67; taxes municipales et frais: $16.51.Total: $35.18.Gabriel Guénette, 8938, 14e Avenue, ville St-Michel.\u2014 Lot 12-10.Un emplacement situé à Saint-Adolphe, comté Argenteuil connu et désigné comme étant le lot numéro dix (10) de la subdivision officielle du lot originaire numéro douze (12) dans le rang VI canton Howard au plan et livre de renvoi officiels dudit canton dans le comté Argenteuil.Avec un chalet dessus construit.Taxes scolaires et frais: $45.04.Municipalité de Morin Heights John William Clark et Gilles Henry Allery.\u2014 Ptie lot 58 et Ptie lot 59, rang 2.Un certain morceau de terrain connu et désigne aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Morin, comme étant composé des lots Nos cinquante-huit et cinquante-neuf (Pties 58 et 59) ledit morceau de terrain mesurant trois cents pieds de largeur sur une profondeur de trois cent pieds (300' x 300').Borné au nord par un ancien chemin du Gouvernement et des trois autres cotés par la propriété du vendeur; la ligne est dudit morceau de terrain étant située à une dislance de cent quatre-vingts pieds (180') mesurés le long dudit chemin à partir de la ligne du premier rang dans ledit canton; avec toutes les btttisses dessus érigées.Enregistré sous l'acte No 70719.Taxes municipales et frais: $20.90; taxes scolaires: $19.26.Total: $40.16.M.Guido Coert, 571, Terrasse Vachon, Ville I-aSallc.\u2014Enregistrement No 92937.Ptie 33, rung III, Un immeuble situé à Morin Heights, comté d'Argenteuil, pris à même le lot de terre connu et désigné sous le numéro trente-trois dans le troisième rang du canton Morin (Ptie 33, rang IH) au cadastre officiel du canton Morin; Cet emplacement mesure trois cents pieds (300') dc largeur dans sa ligne sud-est, et deux cent quarante pieds (240') de largeur dans sa ligne nord-ouest, sur trois cents pieds (300') de profondeur dans sa ligne nord-est, et deux cent soixante-dix pieds (270') dans sa ligne de côté sud-ouest, mesure anglaise, plus ou moins.Cet emplacement est borné comme suit: En avant vers le sud-est par le chemin public; d'un côté vers le nord-est par une autre partie du lot No 33, rang DU, la propriété de M.Sabourin ; de l'autre côté vers le sud-ouest et en arrière vers le nord-ouest par d'autres parties du lot No 33, rang III, demeurant la propriété du vendeur.Ainsi que le tout se trouve actuellement avec in the comity of Argenteuil.School taxes and costs: $13.50; municipal taxes and costs: $9.81.Total: $23.31.Jacques Clermont, 5529, 3rd Avenue, Rose-mont, Québec.\u2014 Lot 8-239, 7-206 to 209.A lot known and designated under lot 239 of the official subdivision of original lot number eight (8) in the sixth range, townsliip of Howard, and under lot numbers 206, 207, 208 and 209 of the official subdivision of original lot number seven (7) in the sixth range, townsliip of Howard on the official plan and book of reference of the said townsliip in the county of Argenteuil.School taxes and costs: $16.84.William Nelson, address unknown.\u2014Lot 10- 110.An emplacement known and designated under lot one hundred and sixteen (116) of the official subdivision of original lot number ten (10) in the sixth range township of Howard, on the official plan and book of reference of the said townsliip, in the county of Argenteuil.School taxes and costs: $18.67; municipal taxes and costs: $16.51.Total: $35.18.Gabriel Guénette, 8938, 14th Avenue, ville Saint-Michel.\u2014 Lot 12-10.An emplacement situated at Saint-Adolphe, comity of Argenteuil, known and designated as being lot number ten (10) of the official subdivision of original lot number twelve (12) on range VI, townsliip of Howard, on the official plan and book of reference of the said townsliip in the comity of Argenteuil.With a chalet constructed thereon.School taxes and costs: $45.04.Municipality of Morin Heights John William Clark and Gilles Henry Allery.\u2014 Pt.lot 58 and Pt.lot 59, range 2.A certain piece of land known and designated in the official plan and in the book of reference of the township of Morin, as being composed of the lots numbers fifty-eight and fifty-nine (Pt.58 and Pt.59) measuring said piece of land three hundred feet wide by a depth of three hundred feet (300'x 300') bounded north by an old Government road, and on the three other sides by the property of the vendor; the eastern line of said piece of land being situated at a distance of one hundred and eighty (180') feet measured along the said road from the line of the first range in said township; with all the buildings thereon erected.Registered Deed No.70719.Municipal taxes and costs: $20.90; school taxes: $19.26.Total: $40.16.M.Guido Coert, 571 Terrace Vachon, Ville La Salle \u2014Registration No.92937.Pt.33, range 111.An immovable situated in Morin Heights, county of Argenteuil, taken from the lot of land known and designated under No.thirty-three in the third range of Morin Townsliip (Pt.33, Rge.HI) on the official cadastre for Morin Township this emplacement measures three hundred feet (300') in width in its southeast line, and two hundred and forty feet (240') in width in its northwest line by three hundred feet (300') in depth in its northeast line, and two hundred and seventy feet (270') in its southwest side line, English measure and more or less.This emplacement is bounded as follows: in front, towards the southeast by the public road; on one side towards the northeast by another part of lot No.33, range III, property of M.Sabourin; on the other side, towards the southwest and in rear towards the northwest by other parts of lot No.33, range IH, remaining the property of the vendor.As the whole now subsists, with all the servitudes active 1812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 88 mars 1969, 101' année, n\" 18 toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, et que l'acquéreur déclare connaître.Taxes municipale: $68.55.Chas.Ross Graham.\u2014Partie du lot No 37, rang 2.Acte d'enregistrement No 67945.Un morceau de terrain situé à Morin Heights, comté d'Argentcuil, pris à même le lot de terrain désigné sous le No trente-sept « A » du deuxième rang (37A, Prie R.2) au cadastre officiel du canton Morin; Le morceau de terrain présentement vendu est décrit comme suit: Commençant à un certain point situé sur l'extrême coin sud de la partie du même lot No 37-A, deuxième rang, appartenant à Gordon W.Conley par acte de vente enregistré sous le numéro 67902, de là, allant vers le sud-est en une ligne droite sur une distance de deux cents pieds (200'), de là, tournant en ligne droite, et suivant le côté nord-ouest du chemin privé sur une distance de soixante-quinze pieds (75'), de là, tournant à droite et allant vers le nord-ouest en ligne droite sur une distance de deux cents pieds (200'), de là, tournant à droite et allant vers le nord-est en ligne droite sur une distance de soixante-quinze pieds (75') jusqu'au point dc départ; mesure anglaise.La ligne dc côté sud-ouest du morceau de terrain présentement vendu est parallèle à mie distance de soixante-quinze pieds (75') de la ligne separative entre les lots numéros 37-A et 38-A tous deux du deuxième rang du canton de Morin.Le morceau de terrain présentement vendu est borné en front vers le sud-est par un passage privé; en arrière vers le nord-ouest et deux côtés vers le sud-ouest et vers le nord-est par d'autres partie du même lot No 37-A, deuxième rang, appartenant au vendeur présent.Ainsi que le tout subsiste présentement, avec les servitudes attachées à ladite propriété; Sans bâtisse.Taxes municipales et frais: $25.68; taxes scolaires: $17.96.Total: $43.64.M.Maurice Guénette, Christieville, Québec.\u2014 Enregistré au No 101187.Pt.No 29A, rang 1.Un emplacement connu et désigné comme étant partie du lot numéro vingt-neuf A (Pt.No 29A) dans le premier rang du canton Morin, aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton dans le comté d'Argenteuil; mesurant soixante-dix pieds en front vers l'est (70'), soixante-cinq pieds (65') de largeur en arrière vers l'ouest par cent pieds (100') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins; borné en front vers l'est par la route Nationale, d'un côté vers le nord par un chemin de quinze pieds (15') appartenant au vendeur, vers le sud par la terre de Paul Groulx ou représentants et en arrière vers l'ouest par Omer Guénette; avec maison y érigée.Compris dans la présente vente un droit de passage en faveur du terrain vendu sur le chemin prive de quinze pieds (15') que le vendeur s'est réservé dans la ligne nord du terrain vendu.Tel que le tout se trouve actuellement avec toutes servitudes actives et passives, apparentes et occultes, attachées audit immeuble, l'acquéreur déclarant le bien connaître et en être satisfait.Taxes municipales: $178.69.Gérard Hébert, 38 Upper Edison, Saint-Lambert, Québec\u2014Enregistré au No 95365.Pt.51A, rang 1.Un emplacement situé à Morin Heights, comté d'Argentcuil, formant partie du lot numéro cinquante et un A (Pt.51A) dans le premier rang, du cadastre officiel du canton Morin.Cet emplacement mesure cent pieds (100') de largeur dans sa ligne nord-ouest, cent quarante-sept pieds (147') de profondeur dans sa ligne and passive, apparent or unapparent, and that the purchaser declares to know.Municipal taxes-$68.55.Clias.Ross Graham.\u2014 Pt.of lot No.37, range 2.Registered Deed No.67945.A piece of land situated at Morin Heights, county of Argenteuil, taken from the lot of land designated under the number thirty-seven A, in the second range, (37A, Pt.Rge.2) of the official cadastre of the township of Morin; the piece of land presently sold is described as follows: Starling at a certain point situated on the extreme south corner of the part of the same lot No.37A, second range, belonging to Gordon W.Conley by deed of sale registered under the number 67902, then going south easterly in a straight line for a distance of two hundred feet (200'), then turning to the right and going southwesterly in a straight line, and following the northwest side of the private passageway for a distance of seventy-five feet (75') thence turning to the right and going northwesterly in a straight line for a distance of two hundred feet (200') thence turning to the right and going northeasterly in a straight line for a distance of seventy-five feet (75') to the point of commencement; English measure; the southwest side line of the piece of land presently sold is parallel to and situated at a distance of seventy-five fect (75') from the dividing line between the lots numbers 37A and 38A both of the second range of the township of Morin; the piece of land presently sold is bounded in the front towards the southeast by a private passageway; at the rear towards the northwest and on both sides towards the southwest and towards the northeast by other parts of the same lot No.37A, second range, belonging to the present vendor; as the whole is now with the servitudes attached to the said property; without building.Municipal taxes and costs: $25.68; school taxes: $17.96.Total: $43.64.Mr.Maurice Guénette, Christieville, Québec.\u2014 Registration No.101187, Pt.No.29A, range 1.An emplacement known and designated as being part of lot number twenty-nine A (P.No.29A) on the first range of the township of Morin, on the official plan and book of reference of the said township in the county of Argenteuil; measuring seventy feet in front on the cast (70'), sixty-live feet (65') in width in the rear, on the west by one hundred feet (100') in depth.English measure and more or less; bounded in front on the cast by National Route, on one side on the north by a road of fifteen fect (15') belonging to the vendor, on the south by the land of Paul Groulx of representatives and in the rear on the west by Omer Guénette; with a house erected thereon.Included in the present sale a right of way in favor of the land sold on the private road of fifteen feet (15') tliat the vendor kept for himself on the north line of the land sold.Such as the whole is presently found with all servitudes, active and passive, apparent and occult, attached to the said immovable, the purchaser declaring it well known and satisfied with it.Municipal taxes: $178.69.Gérard Hébert, 38 Upper Edison, Saint -Lambert, Québec \u2014 Registration No.95365, Pt.51A, range 1.An emplacement situated at Morin Heights, county of Argenteuil, forming part of lot number fifty-one A (Pt.51 A) on the first range of the official cadastre of the township of Morin.This emplacement measures one hundred feet (1000 in width on its northwest line, one hundred and forty-seven fect (1470 'n depth on its south QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1813 sud-ouest, et cent trente-sept pieds (137') de profondeur dans sa ligne nord-est, mesure anglaise, plus ou moins, sans bâtisse.Cet emplacement est borné comme suit: un avant vers le sud-est par le chemin privé existant qui conduit au chemin public portant le No 51A-41, rang un; en arrière vers le nord-ouest par une autre partie dudit lot No 51 A, rang 1, la propriété du présent acquéreur; d'un dite vers le sud-ouest par le lot No 51A-1 la propriété dc Mme L.Vankooi; de l'autre côté vers le nord-est par une autre partie dudit lot 51 A, rang 1, demeurant la propriété du vendeur.Ainsi que le tout se trouve actuellement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, et que l'acquéreur déclare connaître.Taxes municipales: $169.08.lad Inc.« The Commons ».\u2014 Lot No Pt.39A, rang 2.No 113289.I.Certains emplacements situés à Morin Heights, dans le second rang du canton Morin, comté d'Argenteuil, Québec, et composés: a) Des lots numéros deux, trois, quatre et cinq dc la subdivision officielle du lot originaire numéro trente-neuf A (39A-2, 3, 4 et 5) des plans et livre de renvoi officiels du canton; b) Dc la partie nord-ouest du lot numéro six dc la subdivision officielle du lot originaire numéro trente-neuf A (39A-Pt.n.o.6) des plan et livre dc renvoi officiels susdits, mesurant cent cinquante-trois pieds (153') du côté sud-ouest, vingt-sept pieds et six pouces (27' 6\") en arrière, cent neuf pieds (109 ) du côté nord-est, par toute sa largeur; bornée au sud-ouest par le lot numéro 39A-5, au nord-est par le lot Xo 39A-7, au nord-ouest par le droit dc passage du Chemin de fer Canadien National et au sud-est partie par le lot No 39A-10 et partie par le résidu dudit lot No 39A-6; r) Dc la partie nord-ouest de la partie nord-ouest du lot numéro sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro trente-neuf A (Pt.n.o.dc Pt.n.o.39A-7) des plan et livre de renvoi officiels susdits, de forme irrégulière, mesurant vingt et un pieds (21') du côté nord-ouest, quatre-vingt-deux pieds et six pouces (82* 6\") dc profondeur du côté nord-est et cent neuf pieds (109') du côté sud-ouest, mesure anglaise et plus ou moins; bornée ladite partie au sud-ouest par partie du lot No 39A-6, au nord-ouest par le droit dc passage du Chemin de fer Canadien National, au nord-est par partie du lot No 39A-7 appartenant à M.René Deniers et nu sud-est par la clôture de la piste de course; (/) Dc la partie nord-est dc la partie nord-ouest du lot numéro sept dc la subdivision officielle du lot originaire numéro trente-neuf A (Pt.n.c.de Pt.n.o.39A-7) des plan et livre dc renvoi officiels susdits, dc forme irrégulière, mesurant quatre-vingts pieds dc largeur du côté nord-ouest et quatre-vingt-deux pieds et six pouces (82' 6\") de profondeur du côté nord-est, mesure anglaise et plus ou moins; bornée au sud-ouest par une autre partie dudit lot No 39A-7 appartenant à M.P.L.Hammond ou représentants, au nord-ouest par le droit dc passage du Chemin dc Fer du Canadien National, au nord-est par les emplacements ci-après décrits et au sud-est par une autre partie dudit lot No 39A-7; la ligne sud-ouest de cette dite partie étant une ligne droite parallèle A la ligne nord-est dudit lot No 39A-7 A une distance dc quatre-vingts pieds (80') dc ladite ligne nord-est; west line, and one hundred and thirty-seven feet (137') in depth on its northeast line, English measure, more or less, without a building.Tlus emplacement is bounded as follows: in front on the southeast by a private road leading to the public road bearing No.51A-41, range one; in the rear on the northwest by another part of said lot No.51A, rge 1, the property of the present purcliaser; on one side on the southwest by lot No.51 A-l the property of Mrs.L.Vankooi; on the other side on the northeast by another part of said lot 51 A, rge 1, remaining the property of the vendor.Such as the whole is presently found with all servitudes, active and passive, apparent and occult, and tliat the purcliaser declares to know.Municipal taxes: $169.08.Jail Inc.\"The Commons\".\u2014 Lot No.Pt.39A.range 2.Registered Deed No.113289.1.Certain emplacements situated at Morin Heights, on the second range of the township of Morin, county of Argenteuil, Québec, and composed: a) Of lot numbers two, three, four and five of the official subdivision of original lot number tliirty-nine A (39A-2, 3, 4 and 5) on the official plan and book of reference of the township; b) The northwest part of lot number six of the official subdivision of original lot number tlurty-nine A (39A Pt.N.W.6), on the official plan ami book of reference aforesaid; measuring one hundred and fifty-three feet (153') on the southwest side, twenty-seven fect and six inches (27' 6\") in the rear, one hundred and nine feet (109') on the northeast corner, by all its width, bounded on the southwest by lot number 39A-5, on the northeast by lot No.39A-7, on the north-West by the right of way of the Canadian National Railway and on the southeast part by lot No.39A-10 and part by the remainder of said lot No.39A-6; c) The northwest part of the northwest part of lot number seven of the official subdivision of original lot number thirty-nine A (Pt.N.W.of Part N.W.39A-7) on the official plan and book of reference aforementioned, of an irregular form, measuring twenty-one feet (21') on the northwest side, eighty-two fect and six inches (82'6\") in depth on the northeast side and one hundred and nine feet (109') on the southwest side, English mcusurc and more or less; hounded the said part, on the southwest by part of lot No.39A-6, on the northwest by the right of way of the Canadian National Railway, on the northeast by part of lot No.39A-7 belonging to Mr.René Deniers and on the southeast by the fence of the race track; d) The northeast part of the northwest part of lot number seven of the official subdivision of original lot number thirty-nine A (Pt.N.E.of Pt.N.W.39A-7) on the official plan and book of reference aforementioned, of an irregular form, measuring eighty fect in width on the northwest side and eighty-two fect and six inches (82' 6\") in depth on the northeast side, English measure and more or less; bounded on the southwest by another part of said lot No.39A-7 belonging to Mr.F.L.Hammond or representatives, on the northwest by the right of way of the Canadian National Railway, on the northeast by the emplacements hcrcuftcr described and on the south-cast by another part of said lot No.39A-7; the southwest line of this said part being a straight line parallel to the northeast line of -aid lot No.39A-7 at a distance of eighty feet (80') from the said northeast line; 1814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, n\" 12 e) Dc parties des lots numéros huit et neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro trente-neuf A (39A Ft.8 et 9) des plan et livres de renvoi officiels susdits; lesquelles parties contiennent ensemble cent quarante et un pieds (141') sur le chemin principal, partant de la piste dc course vers le droit de passage du Chemin de Fer du Canadien National, et quarante-huit pieds (48') en arrière il partir dc ladite piste de course et vers le chemin privé, la ligne de division entre lesdits lots mesurant deux cents pieds (200') de profondeur, le tout mesure anglaise et plus ou moins; lesdites parties formant un emplacement borné en front par le chemin principal et en arrière par ladite partie du lot numéro 39A-7 ci-dessus désignée, du côté nord-ouest par un chemin privé et au sud-est par la clôture de la piste de course.Avec bâtisses dessus érigées connues sous le nom de « The Commons\" et toutes dépendances y attachées.Tel que le tout se trouve actuellement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées auxdits immeubles, sans réserve, sujets aux droits de passage mentionnés dans les ventes enregistrées au bureau d'enregistrement du comté d'Argenteuil sous les numéros 50971 et 57872.2.Certains emplacements également situés à Morin Heights, dans le second rang du Canton Morin, comté d'Argenteuil, Québec, et composés; a) Dc la partie du lot numéro six de la subdivision officielle du lot originaire numéro trente-neuf A (39A pt.0) des plan et livre de renvoi officiels du canton Morin, bornée dans sa ligne sud-est par le lot numéro 39A-10, dons sa ligne nord-est par le lot No 39A-7 ci-après décrit et dans sa ligne ouest par partie du lot numéro 39A-0 appartenant au présent vendeur.b) De la partie du lot numéro sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro trente-neuf A (39A pt.7) des plan et livre de renvoi officiels susdits, bornée dans sa ligne sud-est par le lot No 39A-10, dans sa ligne nord-est par le lot numéro 39A-9 ci-après décrit, dans sa ligne nord-ouest par partie du lot numéro 39A-7 appartenant au présent vendeur et dans sa ligne sud-ouest par partie du lot numéro 39A-6 ci-dessus décrit.c) De la partie du lot numéro neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro trente-neuf A (39A pt.9) des plan et livre de renvoi officiels susdits, bornée dans sa ligne sud-ouest par le lot No 39A-10 et par partie du lot No 39A-9 appartenant à « The St.John Ambulance Association » aux termes d'un acte passé devant Me Conrad Laberge, notaire, le 20 octobre 1950, enregistré au bureau d'enregistrement d'Argenteuil sous le numéro 70387, de même qu'aux termes d'un acte de correction passé devant Me George Leonard, notaire le 15 septembre 1902, portant le numéro 5624 de son répertoire, dans sa ligne sud-ouest par partie du lot No 39A-7 ci-dessus décrit, dans sa ligne nord-ouest par partie du lot numéro 39A-9 appartenant au présent vendeur et dans sa ligne nord-est par partie du lot numéro 39A-9 appartenant à \"The St.John Ambulance Association\".Tel que le tout est plus amplement détaillé à un plan préparé par M.Jean René Duhai-me, a.o., en date du neuf janvier mil neuf cent soixante et un (1961) dont copie a été anntxée à l'original des présentes, après avoir été reconnue (e) Part of lot numbers eight and nine of the official subdivision of original lot number thirty-nine A (39A Pt.8 and 9) on the official plan and book of reference aforementioned; which parts contain altogether one hundred and forty-one feet (141') on the principal road, starting from the race track to the right of way of the Canadian National Railway, and forty-eight feet (-18') in the rear starting from the said race track and to the private road, the division line between the said lots measuring two hundred feet (200') in depth, the whole English measure and more or less; the said parts forming an emplacement bounded in front by the principal road and in the rear by the said part of lot number 39A-7 here-above designated, on the northwest side by a private road and on the southeast by the fence of the race track.With buildings erected thereon known under the name of \"The Commons\" and all dependen-cies attached thereto.Such as the whole is presently found with all servitudes active and passive, apparent, or occult attached to the said immovables, without reservation, subject to the rights of way mentioned in the sales registered at the registry office of the county of Argenteuil under numbers 56971 and 57872.2.Certain emplacements also situated at Morin Heights, in the second range of the township of Morin, county of Argenteuil, Québec, and composed: (a) Part of lot number six of the official subdivision of original lot number tliirty-nine A (39A Pt.6) on the official plan and book of reference of the township of Morin, bounded on its southeast line by lot number 39A-10, on its northeast line by lot No.39A-7 hereafter described and on its west line by part of lot number 39A-0 belonging to the present vendor; (i) Part of lot number seven of the ollicial subdivision of original lot number thirty-nine A (39A Pt.7) on the official plan and book of reference aforesaid, bounded on its southeast line by lot No.39A-10, on its northeast line by lot No.39A-9 hereafter described, on its northwest line by part of lot number 39A-7 belonging to the present vendor and on its southwest line by pari of lot No.39A-6 hereobove descril>cd; (c) Part of lot number nine of the official subdivision of original lot number thirty-nine A (39A Pt.9) on the official plan and book of reference aforementioned, bounded on its southwest line by lot No.39A-10 and by part of lot No.39A-9 belonging to \"The St.John Ambulance Association\", according to the terms of a deed passed before Me Conrad Laberge, notary, on October 20, 1950, registered at the registry office of Argenteuil under number 70387, as well as according to the terms of a correction deed passed before Me George Leonard, notary, on September 15, 1962, bearing number 5624 of his repertory, on its southwest line by part of lot No.39A-7 hercabove described, on its northwest line by part of lot No.39A-9 belonging to the present vendor and on its northeast line by part of lot No.39A-9 belonging to \"The St.John Ambulance Association\".Such as the whole is more fully detailed in a plan prepared by Mr.Jean-René Duhaime, L.s., dated the ninth day of January one thousand nine hundred and sixty-one (1961) whose copy was annexed to the original of the presents, after QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1815 veritable et signée Ne Varietur par les parties aux présentes en présence du notaire soussigné.Sont également inclus dans la présente vente, sans garantie aucune de la part du vendeur, tous droits, intérêts et prétentions que peut avoir le présent vendeur dans le lot numéro dix dc la subdivision officielle du lot originaire numéro trente-neuf A (39A-10) dudit cadastre.Le présent acquéreur s'engngeant cependant par les présentes, de respecter tous droits, intérêts et prétentions qui existent en faveur de tierces personnes relativement à cedit lot.Tel que le tout se trouve avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes y attachées, sans réserve.Taxes municipales et frais: 81,285.43; taxes scolaires catholiques et frais: $1,475.45; taxes scolaires protestantes: 8649.29.Total: $3,410.17.Succession Chas.Nock.\u2014 Lot 31 C, rang 2.Acte d'enregistrement No 60754i Un morceau ou parcelle de terrain, situé et s'étendant et étant dans la partie sud du canton de Morin, dans ledit comté d'Argenteuil, connue et désignée aux plan et livre de renvoi officiels de la municipalité do la partie sud du canton de Morin comme étant une partie du lot numéro trente et un C (No 31C) rang deux (2) s'étendant sur le côté sud du chemin principal un morceau de terrain de forme irrégulière.Ledit morceau de terrain borné du côté nord par le chemin public, du côté ouest par la propriété de J.A.McConnell, à l'est par le terrain de Carolus Guénette, et au sud par le terrain de Mlle F.Benoit; la propriété ci-dessus décrite ayant une devanture dc quarante-cinq pieds (45') sur une profondeur de soixante (60') pieds, de là à l'est dix pieds (10') dc ce point une distance de quatre'-vingt-cinq pieds (850 à la ligne dc Mlle F.Benoit, et ayant une largeur de trente-cinq pieds (35') en arrière; le long de la limite est est de cent quarante-cinq pieds (145') avec mie maison et autres bâtisses dessus érigées.Taxes municipales et frais: $133.61; taxes scolaires: $138.25.Total: $271.86.M.Jacques Saunier, 51, boulevard Léger, l'ont Viau, Québec.\u2014 Enregistrement No 108593.Pt, 31, range III.Un emplacement situé à Morin Heights, formant partie du lot numéro trente et un dans le troisième rang (pt.31, rg III) du cadastre officiel du canton Morin.Cet emplacement mesure quatre cents pieds (4000 de largeur le long dc l'ancien chemin public sur quatre cents pieds (400') de profondeur, mesure anglaise, sans bâtisse dessus érigée.Cet emplacement est borné comme suit: en avant vers le sud-ouest par l'ancien chemin; en arrière vers le nord-est par une autre partie du lot No.31, demeurant la propriété du vendeur; d'un côté vers le sud-est par la ligne dc division des lots 31, rang II et 32A, rang II dudit cadastre vers le nord-ouest par une autre partie dudit lot No.31, la propriété dc M.André Thcpenicr par acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté d'Argenteuil sous le No 92429 sur une distance de trois cents pieds.Ainsi que le tout se trouve actuellement avec toutes les servitudes active et passives, apparentes et occultes, et que l'acquéreur déclare connaître.Taxes municipal: $74.53.Succession Jas.Tcllicr, 385, avenue Clarcmont, Montréal, Québec.\u2014Pt.lot 41, rang 1, Canton Morin.Environ 1 acre avec bâtisses dessus érigées, bornée en front à l'est par le chemin du lac Echo, à l'ouest par le lac Écho, au nord por le terrain appartenant à la succession de H.Mil- having been acknowledged to be true and signed \"Ne Varietur\" by the parties for the presents in the presence of the undersigned notary.Are also included in the present sale, without any guarantee from the part of the vendor, all rights, interest and pretentions which the present vendor may have on lot number ten of the official subdivision of original lot number thirty-nine A (39A-10) of the said cadastre.The present purcliaser however hereby promises to respect all rights, interest and pretentions which exist in favor of third parties in relation to the said lot.Such as the whole is found with all servitudes, active and passive, apparent or occult attached thereto, without reservation.Municipal taxes and costs: $1,285.43; Catholic school taxes and costs: $1,475.45; Protestant school taxes: $649.29.Total: $3,410.17.Estate Chas.Nock.\u2014 Lot 31C, range 2.Registered deed No.60754.A piece or parcel of land, situate, lying and being in the south part of township of Morin, in the said county of Argenteuil, known and designated on the official plan and book of reference of the municipality of the south port of the township of Morin, under part of lot number thirty-one C (No.31C) range two (2) lying on the soul h side of the main road a piece of land of irregular shape.Said piece of land bounded on the north side by the public road, on the west side by the property of J.A.McConnell, on the east by the land of Carolus Gucnette, and on the south by the land of Miss F.Benoit; the property nbove described having a frontage of forty-five fect (45') for a depth of sixty feet (60') thence cast ten feet (10') from this point a distance of eighty-five feet (85') to the line of Miss F.Benoit, and having a width of thirty-five feet (35') in the rear; the length of the eastern boundary is one hundred and forty-five feet (145') with a house and other buildings thereon erected.Municipal taxes and costs: $133.01; school taxes: $138.25.Total: $271.86.Mr.Jacques Sannier, 51, boulevard Léger, Pont Viau, Québec.\u2014Registration No.108593, Pt.31, range III.An emplacement situated at Morin Heights, forming part of lot number thirty-one in the third range (Pt.31, rge HI) on the official cadastre for the township of Morin.This emplacement measures four hundred feet (400') in width along the former public road by four hundred fect (400') in depth, English measure, without building thereon erected.This emplacement is bounded as follows: in front towards the southwest by the former road, in rear towards the northeast by another part of lot No 31 remaining the property of the vendor; on a side towards the southeast by the division line of lots 31, rge II and 32A, rge II on the said cadastre, towards the northwest by another part of said lot No.31, property of Mr.André Thepenier by deed registered at the registry office of the county of Argenteuil under No.92429, on a distance of three hundred feet.As the whole now subsists, with all the servitudes active and passive, apparent or unapparent, and that the purcliaser declares to know.Municipal taxes: $74.53.Estate Jas.Teilier, 385 Claremont Ave, Montreal, Québec.\u2014 Pt.lot 41, range 1, township of Morin.About 1 acre with buildings thereon erected, fronting on the east by Lake Echo Road, on the west by lake Echo, on the north by land owned by Estate H.Millar, on the south 1816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, n° 12 lar, au sud par un chemin privé, plus détaillé par l'acte No 51628.Taxes municipales et frais: $277.59.H.W.Fisher, Morin Heights, Québec.\u2014 Partie du lot 36, rang 2, canton de Morin.Environ }4 d'acre avec maison dessus érigée, bomée au nord par un chemin privé de la sixième avenue allant vers l'est et l'ouest du lot 36 appartenant à Mme A.F.Copple, à l'est par un terrain appartenant à Mlle Rita Carroll, au sud par le terrain appartenant à Mme A.F.Copple.Taxes municipales et frais: $621.52.Mme Jolin Edward Watchorn, Morin Heights, Québec.\u2014 Lot No 45, rang II, canton de Morin.Une parcelle de terrain coimue et désignée comme étant le lot numéro quarante-cinq du deuxième rang (45, rg.II) au cadastre officiel du canton de Morin, moins les parties vendues par actes enregistrés au bureau d'enregistrement d'Argenteuil sous les numéros 54322, 55361, 60300, 02787, 69116.72183, 103,257 et 116,582 ainsi que le tout subsiste présentement avec toutes les servitudes qui peuvent y être attachées.Taxes municipales: $72.24.R.E.Grenon, adresse inconnue.\u2014 Lot No 50B-13, rang 2, Morin.La subdivision treize (13) du lot originaire numéro cinquante, lettre B (50B), rang deux (rg 2) aux plan et livre de renvoi officiels de Morin.Avec les bâtisses dessus érigées.Taxes municipales et frais: $254.53.Paul Gélinas, Sainte-Agathe des Monts, Québec.\u2014 Pt.29B, rang 2, canton de Morin.Description dc l'acte No 112930.Cet emplacement situé en la municipalité de Morin Heights dans le comté d'Argenteuil, de figure irrégulière, faisant partie du lot originaire numéro vingt-neuf B (Pt.29B) dans le deuxième rang du canton Morin.au cadastre officiel dudit canton, division d'enregistrement du comté d'Argenteuil et plus particulièrement décrit comme suit savoir: Partant d'un point situe à une distance dc trois cent deux pieds (302') du chemin public Sainte-Adèle-Morin Heights et à une distance de trente-trois pieds (33') de la ligne qui sépare ledit lot originaire numéro 29B du lot numéro 30, de là se dirigeant dans une direction nord-ouest, en suivant le côté nord-est d'une rue de trente-trois pieds (33') de largeur faisant partie dudit lot originaire numéro 29B sur une distance de deux cents pieds (200') de là tournant à un angle de cinquante-sept degrés et cinquante-neuf minutes (57 59') dans une direction nord-est, le long d'une rue faisant partie dudit lot originaire numéro 29B sur une distance de deux cent cinquante-deux pieds et huit dixièmes de pied (252.8') de là tournant à un angle dc cent quatorze degrés et vingt minutes (114° 20') dans une direction sud-est, sur une distance de cent pieds (100') jusqu'à un quatrième point situé à une distance de ceux cents pieds (200') du côté nord-ouest du chemin public Morin Heights-Sainte-Adèle; de là tournant à angle droit et se dirigeant dans une direction sud-ouest, sur une distance de deux cent trois pieds et cinq dixièmes de pied (203.5') pour rencontrer le point d'origine, lequel est situé; à une distance de trois cent deux pieds (302') du chemin public Morin Heights-Sainte-Adèle et à trente-trois pieds (33') de la ligne qui sépare ledit lot originaire numéro 29 du lot numéro 30, et lequel emplacement est borné comme suit: savoir, vers le sud-ouest, par une rue de trente-trois pieds (33') de largeur faisant partie dudit lot originaire numéro 29B vers le nord par une autre rue faisant partie by a private road, more covered by deed No.51628.Municipal taxes and costs: $277.59.H.W.Fisher, Morin Heights, Québec\u2014 Part of lot 36, range 2, township of Morin.About acre with house thereon erected, bounded on the north by a private road from Sixth Avenue running east and west of lot 36 owned by Mrs.A.F.Copple, on the east by land owned by Miss Rita Carroll, on the south by land owned by Mrs, A.F.Copple.Municipal taxes and costs: $621.52.Mrs.John Edward Watchorn, Morin Heights, Québec.\u2014 Lot No.45, range II, township of Morin.A parcel of land known and designated as lot number forty-five of the second range (15, rge II) of the official cadastre of the township of Morin, less parts sold by deeds registered at Argenteuil registry office under numbers: 51322.55301, 60300, 62787, 69116, 72183 103,257 and 116,582, as the whole now subsists with all the servitudes which may be attached thereto.Municipal taxes: $72.24.R.E.Grenon, address unknown.\u2014 Lot No.50B-13 range 2, Morin.Subdivision thirteen (13) of the original lot number fifty, letter B (50B) range two (rge 2) of the official plan and book of reference of the township of Morin.With buildings thereon erected.Municipal taxes and costs: $254.53.Paul Gélinas, Sainte-Agathe des Monts, Québec.\u2014: Pt.29B range 2 township of Morin, description of deed No.112930.This emplacement situated in the municipality of Morin Heights in the county of Argenteuil, of an irregular figure, being part of original lot number twenty-nine B (Pt.29B) on the second range of the township of Morin, on the official cadastre of the said township, registration division of the county of Argenteuil, and more fully described as follows, to wit: Starting from a point situated at a distance of three hundred and two feet (302') from the public road of Sainte-Adèlc-Morin Heights and at a distance of thirty-three fect (33') from the line which separates the said original lot No.2911 from lot number 30, thence going in a northwesterly direction, following the northeast side of a street of thirty-three feet (33') in width lx-ing part of said original lot number 29B a distance of two hundred feet (200') thence turning at an angle of fifty-seven degrees and fifty-nine minutes (57° 59') in a northeasterly direction, along a street being part of said original lot No.29B on a distance of two hundred and fifty-two feet and eight tenths of a foot (252.8') thence turning to an angle of one hundred and fourteen degrees and twenty minutes (114° 20') in a southeasterly direction, on a distance of one hundred feet (101)') up to a fourth point situated at a distance of two hundred feet (200') on the northwest side of Morin Heights-Sainte-Adèle public road: thence turning at a right angle and goint in a southwesterly direction, on a distance of two hundred and three feet and five tenths of a foot (203.5') to meet the original point, which is situated; at a distance of three hundred and two fect (302') from the Morin Heights-Sainte-Adèle public road and at thirty-three feet (33') from the line separating the said original lot number 29 from lot number 30, and which emplacement is bounded as follows: to wit: on the southwest by a street of thirty-three feet (33') in width being part of said original lot number 29B on the north by another street being part of said original lot QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, I960, Vol.101, No.12 1817 dudit lot originaire numéro 29IJ vers le nord-est par une autre partie dudit lot originaire numéro 29B appartenant il M.André Basticn ou représentant et vers le sud-est, par une autre partie ilmlit lot originaire numéro 29B appartenant à M.André Bastion ou représentants; (Jet emplacement est montré entouré d'un tracé rouge sur un certificat dc localisation préparé par Robert Michaud, a.g.le sept novembre mil neuf cent soixante, sous le numéro 2051 de ses contrats et dont copie est annexée ù un acte île prêt par Dame Jeanne Payette épouse de M.Walter G.Schmidt consenti à André Bostien ¦levant Me.A.Voizard, le 23 novembre 1960, sous le No 5083 de ses minutes et dont acte a été enregistré à Argenteuil sous le No 93472.Avec toutes les bâtisses y érigées circonstances et dépendances.Taxes municipnlcs: $469.30; frais: $65.11.Total: $534.41.[,a commission scolaire régionale protestante dc Morin James Ilea ton, fils, adresse inconnue.\u2014 Lot Xo 51-25, rang 3.Acte enregistré No 91425.Un certain morceau de terrain vacant situé dans la municipalité dc Morin Heights, province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision vingt-cinq du lot originaire cinquante et un (51-25) dans le troisième rang dudit canton de Morin, aux plan et livre dc renvoi officiels dudit canton dans le comté d'Argentcuil, mesurant cent quarante pieds (140') de largeur sur une profondeur de deux cents pieds (200'), ayant une superficie de vingt-sept mille six cent pieds carrés (27,600' p.c), Mesure anglaise et plus ou moins ainsi que le tout subsiste présentement.Taxes scolaires: $32.06.Mme Robert Lloyd Johnston, adresse inconnue.- Lots Nos.51-11, rang 2 et 50-20, rang 2.Acte enregistré No 108307.Un certain emplacement situé dans le canton dc Morin, dans le comte d'Argentcuil, et composé de: ii) La subdivision onze du lot originaire cinquante et un du deuxième rang (51-11 rg 2) aux plan et livre dc renvoi officiels du canton de Morin./») La subdivision vingt du lot originaire cinquante du deuxième rang (50-20 rg 2) auxdits plan et livre de renvoi officiels.Le tout ayant une superficie dix-sept mille cinq cent cinquante-uenf pieds carrés (17,559 p.c).Mesure anglaise et plus ou moins.Ainsi que le tout subsiste présentement.Taxes scolaires: $28.11; taxes municipales: $31.03.Total: $59.14.K.C.McLean, adresse inconnue.\u2014 Lot Nos 51-12 et 50-21, rang 2.Acte enregistré No 107983.\u2014Un certain emplacement situé dans le canton de Morin, comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant ln subdivision douze du lot originaire cinquante et un et la subdivision vingt et un du lot originaire cinquante du deuxième rang (51-12 et 50-21 rg 2) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de .Morin, ayant une superficie dc vingt-quatre mille cent quatre-vingt-un pieds carrés (24,181 p.c), mesure anglaise et plus ou moins.Ainsi que le tout subsiste présentement.Taxes scolaires: $29.68.Mlle Eileen O'Hcarn, adresse inconnue.\u2014 Lot No 50-69, rang 3.Acte d'enregistrement No 92977.Un certain emplacement situé dans le canton île Morin, paroisse de Morin Heights, comté d'Argenteuil, connu et désigné comme «'tant la subdivision soixante-neuf du lot originaire cinquante (50-69) aux plan et livre de number 29B on the northeast by another part of said original lot number 29B' belonging to Mr.André Bastien or representative and on the southeast by another part of said original lot number 29B belonging to Mr.André Bastien or representatives; This emplacement is shown encircled by a red mark on a certificate of locality prepared by Robert Michaud, l.s., on the seventh day of November, one thousand nine hundred and sixty, under number 2051 of its contracts and a copy of which is annexed to a deed of loon by Mrs.Jeanne Poyette wife of Mr.Walter G.Schmidt ugrced to by André Bastien before Me.A.Voizard on November 23, 1960, under No.5083 of its minutes and a copy of which was registered at Argenteuil under No.93472.With all buildings erected thereon, circumstances and dependencies.Municipal taxes: $469.30: costs: $05.11.Total: $534.41.Morin Heights Protestant School Board James Beaton Jr., address unknown.\u2014 Lot No.51-52, range 3, registered deed No.91425.A certain vacant piece of land located in the municipality of Morin Heights, Province of Québec,.known and designated as being subdivision twenty-five of the original lot fifty-one (51-25) on the third range of the said township of Morin, on the official plan and book of reference of the said township in the county of Argenteuil, measuring one hundred and forty feet (140') in width by two hundred feet (200') in depth, having a superficial area of twenty-seven thousand six hundred square feet (27,600' sq.ft).English measure and more or less.As the whole now subsists.School taxes: $32.00.Mrs.Robert Lloyd Johnston, address unknown.\u2014 Lots Nos.51-11 range 2 and 50-20 range 2, registered deed No.108307.A certain emplacement located in the township of Morin, in the county of Argenteuil, and composed of: (a) Subdivision eleven of the original lot fifty-one of the second range (51-11 Rge.2) on the official plan and book of reference of the townsliip of Morin.(Ii) Subdivision twenty of the original lot fifty of the second range (50-20 Rge.2), on the said official plan and book of reference.The whole having a superficial area of seventeen thousand five hundred and fifty-nine square fect (17,559' sq.ft).English measure and more or less.As the whole now subsists.School taxes: $28.11; municipal taxes: $31.03.Total: $59.14.K.C.McLean, address unknown.\u2014 Lot Nos 51-12 and 50-21, range 2.Registered deed No.107983.A certain emplacement located in the township of Morin, county of Argenteuil, known and designated as being subdivision twelve of the original lot fifty-one and subdivision twenty-one of the original lot fifty of the second range (51-12 and 50-21 Rge 2) on the official plan and book of reference of the township of Morin, having a superficial area of twenty-four thousand one hundred and eighty-one square fect (24,181 so.ft.) English meaure and more or less.As the whole now subsists.School taxes: $29.08.Miss Eileen O'Hcarn, address unknown.\u2014 Lot No.50-69, range 3.Registered Deed No.92977.A certain emplacement located in the townsliip of Morin, parish of Morin Heights, county of Argenteuil, known and designated as being subdivision sixty-nine of the original lot fifty (50-69) on the official plan and book o 1818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mare 1969, 101' année, n\" 12 renvoi officiels du troisième rang dudit canton de Morin; ayant une superficie de dix-sept mille huit cents pieds carrés (17,800 p.c.) mesure anglaise et plus ou moins.Ainsi que le tout subsiste présentement.Taxes scolaires: $134.02.Wabasso Camp Inc., a/s dc M.W.Sinclair, 734-40c avenue Lachine.\u2014 Lots Nos 10-2, 3,4, 5, 6, 7, 54, 55, 56.58, 57 et 59, rang 11.Acte d'enregistrement No 38848.Un certain cmpla-nient de terrain s'étendant et étant dans le canton dc Wcntworth dans le comté d'Argentcuil, en la province dc Québec, comprenant les numéros dc lots dc la subdivision officielle: deux, trois, quatre, cinq, six, sept, cinquante-quatre, cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-huit, cinquante-sept et cinquante-neuf «lu lot connu et désigné aux plan et livre dc renvoi officiels dudit canton «le Wcntworth sous le numéro dix dans le onzième rang d'icclui, Nos 10-2, 3, 4, 5, 0, 7, 54, 55, 56, 58, 57 et 59, rang 11.Taxes municipales: $240.90; taxes scolaires: $225.08.Total: $466.04.Commission scolaire du canton de Morin Florent Beaudin, adresse inconnue\u2014Lot No 50B-40, rang 1, canton dc Morin.Enregistré-sous le No 106226.Un lot «le terrain sis et situé dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant le lot numéro quarante dc la subdivision officielle du lot originaire numéro cinquante B (50B-40) sur le plan et livre de renvoi officiels du premier rang du canton dc Morin.Ainsi que le tout se trouve actuellement avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble.Taxes municipales et frais: $88.64; taxes scolaires et frais: $246.20.Total: $334.84.Pierre Gauthier.\u2014 Lot No 28-153.Canton «le Morin.Enregistré sous le No 111739.Un terrain vacant situé i\\ Morin Heights, comté d'Argentcuil, connu et désigné sous le numéro cent cinquante-trois dc la subdivision officielle du lot originaire numéro vingt-huit du deuxième rang, (28-153) rang 2 sur le plan et au livre «le renvoi officiels du canton Morin, division «l'enregistrement d'Argenteuil à Lachute, contenant dix mille six cent quatorze pieds carrés, mesure anglaise.Tel que le tout se trouve présentement, avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble.Taxes scolaires et frais: $29.66.L.Dcquoy.\u2014 Pt.51 A, rang 1, canton dc Morin.Enregistré sous le No 98510.Un emplacement dc forme irrégulière situé à Morin Heights comté d'Argenteuil, formant partie «lu lot numéro cinquante et un A dans le premier rang (pt.51 A, rg 1) du cadastre officiel «lu canton Morin.Cet emplacement mesure cent onze pieds et trois dixièmes de pied (111.3') dans sa ligne nord-ouest; cent cinquante pieds (150') dans sa ligne sud-ouest; vingt-cinq pieds (25') dans sa ligne sud-est; et cent soixante-quinze pieds (175') dans sa ligne est, mesure anglaise plus ou moins sans bâtisse.Cet emplacement est borné comme suit; vers le nord-ouest pnr un chemin portant le No 51A-65 rg 1 ; vers l'est par un autre chemin portant le No 51A-41, rg 1; vers le sud-ouest par une autre partie dudit lot, la propriété du présent acquéreur; vers le sud-est par une autre partie dudit lot, demeurant la propriété du vendeur ou représentants.Taxes scolaires: $559.45.J.-M.Oucllet.\u2014 Pt.27A, range 2.Enregistré sous le No 91929.Un emplacement de forme reference of the third range of the said townsliip of Morin; having a superficial area of seventeen thousand eight hundred square fect (17,800 sq, ft.) English measure and more or less.As the whole now subsists.School taxes: $134.92.Wabasso Camp Inc., c/o Mr.W.Sinclair, 734-40tli Ave, Lachine.\u2014 Lots Nos.10-2, 3, 4, 5, 6, 7, 54, 55, 56, 58, 57 and 59, range 11.Keg-istered Deed No.38848.A certain emplacement of land lying and being in the township of Wentworth in the county of Argenteuil, in Hie province of Québec, consisting of the official subdivision lots numbers two, three, four, live, six, seven, fifty-four, fifty-five, fifty-six, fifty, eight, fifty-seven and fifty-nine of the lot known and designated upon the official plan and book of reference of the said township of Wentworth under the number ten in the eleventh range thereof, Nos.10-2, 3, 4, 5, 6, 7, 54, 55, 56, 58, 57 and 59, range 11.Municipal taxes: $240.96; School taxes: $225.08.Total: $466.04.School Commission of the Township ol Morin Florent Beaudin, address unknown.\u2014 Lot No.50B-40, range 1, township of Morin.Registered under No.106226.A lot of land being and situated in the county of Argenteuil, known and designated as being lot number forty of the official subdivision of original lot number fifty B (5011-10) on the official plan and book of reference of the first range of the township of Morin.Such as the whole is presently found with all servitudes, active and passive, apparent or occult attached to the said immovable Municipal taxes and costs: $88.64; School taxes and costs: $240.20.Total: $334.84.Pierre Gauthier.\u2014Lot No.28-153, townsliip of Morin.Registered under No.111739.A vacant piece of land situated at Morin Heights, county of Argenteuil, known and designated under number one hundred and fifty-three of the official subdivision of original lot number twenty-eight on the second range, (28-153) range 2 on the official plan and book of reference of I he township of Morin, registration division of Argenteuil at Lachute, containing ten thousand six hundred and fourteen square feet, English measure.Such as the whole is presently found, with all servitudes, active and passive, apparent or occult attached to the said immovable School taxes and costs: $29.66.L.Dequoy.\u2014 Pt 51A, range 1, township of Morin.Registered under No.98510.An emplacement of an irregular form, situated at Morin Heights, county of Argenteuil, forming part of lot number fifty-one A in the first range (Pt 51 A.R.1) of the official cadastre of the township of Morin.This emplacement measures one hundred and eleven feet and three tenths of a foot (111.3*) on its northwest line; one hundred and fifty fect (150') on its southwest line; twenty-five feet (25') on its southeast line; and one hundred and seventy-five feet (175') on its cast line, English measure more or less without a building.This emplacement is bounded as follows; on the northwest by a road bearing No.51 A-65 R.1; on the east by another road bearing No.51A-41 11.I; on the southwest by another part of the said lot, the property of the present purchaser; to the sou t h -cast by another part of the said lot, remaining the property of the vendor or representatives.School taxes: $559.45.J.-M.Ouellet.\u2014 Pt 27A, range 2.Registered under No.91929.An emplacement of an irregular QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1819 irrégulière situé à Morin Heights, comté d'Argentcuil formant partie du lot connu et désigné sous le numéro vingt-sept A dans le deuxième rang (pl.27A, rg 2) du cadastre officiel du canton Morin.Cet emplacement mesure deux cent treize pieds (213') dans sa ligne nord-ouest et cent cinq pieds (105') dans sa ligne nord-est, cinq cent trente-neuf pieds (539') dans sa ligne sud-ouest et environ quatre cent quatre-vingt-huit pieds (488') dans sa ligne est le long du chemin privé existant qui mesure douze pieds dc largeur, mesure anglaise, plus ou moins, sans lmtis.se.Cet emplacement est borné comme suit: vers le nord-ouest et le nord-est par d'autres parties dudit lot demeurant la propriété du vendeur; vers l'est par un chemin privé, qui est une autre partie dudit lot 27A rg 2, la propriété du vendeur; vers le sud-ouest par une autre partie dudit lot, la propriété du présent acquéreur par acte de vente enregistré sous le No 87589.Taxes municipales et frais: $49.30; taxes scoluires et frais: $124.27.Total: $173.57.Bernard Blanchet, 10027, rue Cobourg, Montréal-Nord.\u2014 Un morceau de terrain situé dans le canton dc Morin, étant une partie du lot connu et désigné sous le numéro quarante-quatre B dans le premier rang (pt.44B, rg 1) dudit canton.Ce morceau dc terrain mesure cent pieds (100*) de largeur sur ses lignes sud-est nord-ouest sur deux cents pieds (200') de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins, sans bâtisse.Ce morceau dc terrain est borné comme suit: l'.ii front vers le sud-est par le chemin public; en arrière vers le nord-ouest par une autre partie du lot No 44, rg 1, propriété des vendeurs; d'un côté, vers le sud-ouest par une autre partie dudit lot, propriété de Kenneth Ross Grccn, par acte de vente enregistré au bureau d'enregistrement du comté d'Argentcuil sous le No 94079; dc l'autre côté vers le nord-est par une autre partie du lot No 44, rg 1, demeurant la propriété des vendeurs.Ainsi que le tout subsiste présentement avec toutes les servitudes y attachées et desquelles l'acheteur se déclare satisfait.Taxes scolaires: $36.77; taxes inunici-pales: $15.75.Total: $52.52.Commission scolaire catholique dc Lachute Edward Beavcn, 330, rue Principale, Lachute, Québec,\u2014 Pt.1297.Un certain morceau dc terre situé dans la ville de Lachute, connu et désigne aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse dc Saint-Jérusalem d'Argenteuil comme étant l'exacte moitié du lot numéro mille deux cent quatre-vingt-dix-sept (Pt.1297) mesurant cent quatre-vingt-dix pieds (190') de profondeur sur cinquante pieds (50') de largeur (50' x 190'); mesure anglaise et plus ou moins, le plus ou le moins desdites mesures étant au bénéfice ou à la perte de l'acheteur; avec bâtisse dessus érigée.Veuillez prendre note que cettedite propriété est grevée d'une somme de $263.23 représentant les taxes municipales ducs à la cité de Lachute et la mise à prix devrait donc être faite en conséquence.Taxes municipales: $263.23; taxes scolaires: $255.34.Total: $518.57.Leopold Girard, 107, Boul.Cruise, Lachute, Québec\u2014 Pt 1402.Un certain emplacement situé en la ville de Lachute connu et désigné aux plan et livre dc renvoi officiels dc la paroisse dc Saint-Jérusalem d'Argentcuil comme formant partie du lot numéro mille quatre cent deux form situated at Morin Heights, county of Argenteuil, forming part of a lot known and designated under number twenty-seven A on the second range (Pt 27A, R.2) of the official cadastre of the township of Morin.This emplacement measures two hundred and thirteen fect (213') on its northwest line and one hundred and five feet (105') on its northeast line, five hundred and thirty-nine feet (539') on its southwest line and approximately four hundred and eighty-eight feet (488') on its cast line along the existing private road which measures twelve feet in width, English measure, more or less, without a building.This emplacement is bounded as follows: on the northwest and northeast by other parts of said lot remaining the property of the vendor; on the east by a private road, which is another part of said lot 27A R.2, the property of the vendor; on the southwest by another part of the said lot, the property of the present purchaser by a deed of sale registered under No.87589.Municipal taxes and costs: $49.30; School taxes and costs: $124.27.Total: $173.57.Bernard Blanchet 10027 Cobourg St., Montreal North.\u2014 A piece of land situated in the township of Morin, being part of lot known and designated under number forty-four-B in the first range (Pt 44B, R.1) of said townsliip.This piece of land measures one hundred feet (100') in width in its southeast and northwest lines, by two hundred feet (200') in depth, English measure, more or less, without buildings.This piece of land is bounded as follows: in the front towards the southeast by the public road; in the back towards the northwest by another part of lot No.44, R.1, the property of the vendors; on one side toward the southwest by another part of said lot the property of Kenneth Ross Green, by deed of sale registered at the registry office for the county of Argenteuil under No.94979; on the other side toward the north-cast by another part of lot No.44, R.1, remaining the property of the vendors.As the whole is now with all servitudes attached and whereof the purchaser declares to be satisfied.Municipal taxes: $15.75; School taxes: $36.77.Total: $52.52.Catholic School Commission of Lachute - Edward Beavcn, 330 Principale St., Lachute, Quebec.\u2014 Pt.1297.A certain piece of land situated in the town of Lachute, known and designated on the official plan and book of reference of the parish of Saint-Jérusalem d'Argenteuil as being the exact half of lot number one thousand two hundred and ninely-scvcn (Pt.1,297) measuring one hundred and ninety fect (190') in depth by fifty fect (50') in width, (50' x 190') ; English measure and more or less, the more or less of the said measurements being beneficial to or a loss for the purcliaser; with a building erected thereon.Please note that this said property is burdened with a sum of $263.23 representing the municipal taxes due to the city of Lachute and the price should be set accordingly.Municipal taxes: $263.23; school taxes: $255.34.Total: $518.57.Leopold Girard, 107 Cruise Blvd.Lachute, Québec.\u2014 Pt.1402.A certain emplacement situated in the town of Lachute, known and designated on the official plan and book of reference of the parish of St.Jerusalem d'Argenteuil as forming part of the lot number one 1820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 19G9, 101' année, n\" 12 (Pt.1402) mesurant deux cent soixante-dix pieds dans la ligne est (270') cinquante pieds dans la ligne sud (50'), soixante pieds dans la ligne nord (60'), la largeur dc la partie nord de remplacement se maintient au chiffre de soixante pieds (60') sur une profondeur de soixante-dix pieds (70'), alors que ladite largeur est réduite à cinquante pieds jusqu'à son extrémité sud, soit une longueur de deux cents pieds (200') borné au nord par la propriété de Gordon P.Cruise et à l'ouest par cette partie du lot 1402 appartenant à Norman Lavis, avec toutes les bâtisses dessus érigées.Veuillez prendre note que cetteditc propriété est grevée d'une somme dc $207.25 représentant les taxes municipales ducs à la cité dc Lachute et la mise à prix devrait donc être faite en conséquence.Taxes municipales: $207.25; taxes scolaires: $173.87.Total: $381.12.François Larocque, 4, rue Fern, Lachute, Québec.\u2014 Lot No 1402-46.Subdivision quarante-six (46) du lot originaire numéro mille quatre cent deux (1402) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Jérusalem d'Argenteuil, en la cité de Lachute, contenant approximativement en superficie 4,990 pieds carrés, mesure anglaise avec les bâtisses dessus érigées.Veuillez prendre note que ladite propriété est grevée d'un montant de $94.76, étant les taxes municipales dues à la cité de Lachute et que le prix demandé devrait être calculé en conséquence.Taxes municipales: $94.76; taxes scolaires: $166.61.Total: $261.37.Jean-Claude Malcttc, 9, Avenue des Pins, Lachute, Québec\u2014Lot No 1403-3, 1406-3.La subdivision trois (3) du lot originaire numéro mille quatre cent trois (1,403) et la subdivision trois (3) du lot originaire numéro mille quatre cent six (1406) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Jérusalem d'Argentcuil, en la cité de Lachute, contenant approximativement une superficie dc 6,923 pieds carrés, mesure anglaise.Veuillez prendre note que ladite propriété est grevée d'un montant de $34.37 étant les taxes municipales dues à la cité de Lachute et que le prix demandé devrait être calculé en conséquence.Taxes municipales: $34.37; taxes scolaires: $70.65.Total: $105.02.Martial Monette, 80, rue Fcrn, Lachute, Québec.\u2014 Lot No 1402-52.La subdivision cinquante-deux (52) du lot originaire numéro mille quatre cent deux (1,402) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse ce Saint-Jérusalem d'Argenteuil, en la cité de Lachute, contenant une superficie approximative de 4,990 pieds carrés, mesure anglaise.Veuillez prendre note que ladite propriété est grevée d'un montant de $161.08 étant les taxes municipales dues à la cite de Lachute et que le prix demandé devrait être calculé m conséquence.Taxes municipales: $161.08; ti-xcs scolaires: 8121.58.Total: 8282.66.Corporation municipale dc la paroisse dc Saint-Jérusalem d'Argentcuil J.I.Gauthier, adresse inconnue.\u2014 Lot pt.1859, Saint-Jérusalem d'Argentcuil.Un certain emplacement connu et désigné au plan et livre dc renvoi officiels de la paroisse de Saint-Jérusalem d'Argenteuil, comme faisant partie du lot numéro mille huit cent cinquante-neuf (pt.1859) mesurant soixante-neuf pieds (69') sur le côté nord soixante-neuf pieds (69') sur le côté thousand four hundred and two (Pt.1,402) measuring two hundred and seventy feet on its east line (270'), fifty feet on its south line (50'), sixty feet on its north line (60') the width of Hie north part of the emplacement remaining at sixty feet (60') by a depth of seventy fect (70'), while the said width is reduced to fifty fect up to its southern extremity, being a length of two hundred feet (200') bounded on the north hy the property of Gordon P.Cruise and on the west by this part of lot 1402 belonging to Norman Lavis, with all buildings erected thereon.Please note that this said property is burdened with a sum of $207.25 representing the municipal taxes due to the city of Lachute and the price should be set accordingly.Municipal laves: $207.25; school taxes: $173.87.Total: $381.12.François Larocque, 4 rue Fern, Lachute, Québec.\u2014¦ Lot No.1402-40.Subdivision forty-six (46) of the original lot number one thousand four hundred and two (1402) of the official plan and book of reference of the parish of Saint-Jerusalem d'Argenteuil, in the city of Lachute, containing in area approximately 4990 sq.ft.E.M.with buildings thereon erected.Kindly take note that the said properly is burdened with an amount of $94.70 being the municipal taxes due to the city of Lachute ami that the upset price should be made accordingly.Municipal taxes: $94.76; school taxes: $166.61.Total: $261.37.Jean-Claude Malettc, 9 Avenue des Pins, Lachute, Québec\u2014Lot No.1403-3, 1406-3.Subdivision three (3) of the original lot number one thousand four hundred and three (14031 and subdivision three (3) of the original lot number one thousand four hundred and six (1406) of the official plan and book of reference of the parish of Saint-Jérusalem d'Argenteuil, in the city of Lachute, containing in area approximately 6,923 sq.ft.English measure.Kindly take note that the said properly is burdened with an amount of $34.37 being the municipal taxes due to the city of Lachute and that the upset price should be made accordingly.Municipal taxes: $34.37; school taxes: $70.65.Total: $105.02.Martial Monette, 80 Fern St., Lachute, Québec.\u2014 Lot No.1402-52.Subdivision fifty-two (52) of the original lot number one thousand four hundred and two (1,402) of the official plan and book of reference of the parish of Saint-Jérusalem d'Argenteuil, in the city of Lachute, containing in area approximately 4,990 square feet English measure.Kindly take note that the said properly is burdened with an amount of $161.08 being I he municipal taxes due to the city of Lachute and that the upset price should be made accordingly.Municipal taxes: $101.08; school taxes: 1121.68.Total: $282.66.Municipal Corporation of the parish of Saint-Jérusalem d'Argenteuil J.I.Gauthier, address unknown.\u2014Loi Pi.1859, Saint-Jérusalem d'Argenteuil.A certain emplacement known and designated on the ollicial plan ami book of reference of the parish of Saint -Jérusalem d'Argentcuil, as being part of loi number one thousand eight hundred and fifty-nine (Pt.1,859) measuring sixty-nine feet (09') on the north side sixty-nine feet (690 on the son'h QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, So.12 1821 sud, cent soixante pieds (160') sur le côté est et cent soixante pieds (ÎÔO1) sur le côté ouest, mesures anglaises et plus ou moins; borné à l'ouest par le chemin public Dunany, au nord par partie du même lot appartenant il Benoit Seguin, à l'est par partie de même lot appartenant à M.Brown ou représentants, et au sud par partie du même lot appartenant au vendeur, Edouard Lapierre sans bâtisse.Contrat numéro 110073.Taxes municipales: $4.19; taxes scolaires: $27.95.Total: $32.14.Les entreprises Argenteuil, Lachute, Québec\u2014 Pt 1712, Saint-Jérusalem d'Argentcuil.Un certain emplacement connu et désigné au plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-.lérusalcm d'Argenteuil comme faisant partie du lot numéro mille sept cent douze (pt.1712) mesurant deux cents pieds (200') sur le côté nord, le long du chemin public numéro 30, cent quatre-vingts pieds (180') sur le côté nord-est, cent cinquante et un pieds (151') sur le côté est, deux cents pieds (200') sur le côté sud, et cent quarante-sept pieds et six pouces sur le côté ouest (147'.6\") borné au nord par le chemin public numéro 30, au nord-est et à l'est un chemin privé situé sur partie dudit lot 1712, au sud sur une largeur de cent pieds par partie dudit lot 1712 de ladite paroisse dc Saint-Jérusalem d'Argentcuil appartenant à Claire Ricndcau ou représentants, et sur une largeur de cent pieds par partie dudit lot 1712 dc la paroisse de Saint-Jérusalem d'Argentcuil appartenant au vendeur ledit Émilien Laurin et à l'ouest par un chemin privé situé sur partie dudit lot 1712 de la paroisse de Saint-Jérusalem d'Argentcuil le tout en mesure nnglaisc et plus ou moins.Le tout tel qu'il se trouve actuellement avec ses servitudes actives et passives apparentes et occultes sans restrictions ni réserve de la part du vendeur.Contrat No.106270.Taxes municipales: $0.90; taxes scolaires catholiques: $32.98; taxes scolaires protestantes: $5.91.Total: $39.79.I).MacRac, U.K.7, Lachute, Québec\u2014 Pt.1919, Saint-Jérusalem d'Argentcuil.Acte Xo 110646.Un certain morceau dc terrain connu et désigné aux plan et livre dc renvoi officiels dc la paroisse dc Saint-Jérusalem d'Argentcuil comme formant partie du lot numéro mille neuf cent dix-neuf (pt.1919) mesurant cent pieds de largeur en front et approximativement cent vingt-cinq pieds en arrière sur une profondeur de cent pieds; borné à l'est par une partie du même lot vendue a Gilbert Demerse, au sud par cette partie du même lot vendue à James llynes et partiellement par le résidu dc la propriété du vendeur et à l'ouest par partie du même lot vendue à Cari Demerse, mesure anglaise, avec les bâtisses dessus érigées.Taxes municipales: $13.74; taxes scolaires: $35.38.Total: $49.12.Louis Patato, 539, rue Dorothy, Greenfield Park, Québec\u2014 Pt.1919, Saint-Jérusalem d'Argentcuil.Acte No 95639.Un certain morceau de terrain situé dans la paroisse de Saint-Jérusalem d'Argentcuil, connu et désigné aux plan et livre de renvoi ollicicl- de ladite paroisse comme étant une portion du lot No mille neuf cent dix-neuf (pt.1919) mesurant cent pieds (100') de chaque côté, borné au nord par Roy Robert-son, à l'est par G.H.Quinn, nu sud par le chemin \u2022'I il l'ouest par Wm E.Hammond.Mesure anglaise, plus ou moins.Ainsi que In propriété subsiste présentement avec toutes les servitudes side one hundred and sixty fect (160') on the cast side and one hundred and sixty feet (160') on the west side, English measure and more or less; bounded on the west by Dunany public road, on the north by part of the same belonging to Benoit Seguin, on the east by part'of the same lot belonging to Mr.Brown or representatives, and on the south by part of the same lot appearing to the vendor, Edouard Lapierre without buildings.Contract number 110073.Municipal taxes: $4.19; school taxes: $27.95.Total: $32.14.Les Entreprises Argenteuil, Lachute, Québec\u2014 Pt.1712, Saint-Jérusalem d'Argenteuil.A certain emplacement known anil designated on the official plan and book of reference of the parish of Saint-Jérusalem d'Argenteuil as being part of lot number one thousand seven hundred and twelve (Pt.1,712) measuring two hundred feet (200') on the north side, along the public road number 30, one hundred and eighty feet (180') on the northeast side, one hundred and fifty-one feet (151') on the cast side, two hundred fect (200') on the south side, and one hundred and forty-seven fect and six inches on the west side (147'6\") bounded on the north by the public road number 30, on the northeast anil cast by a private road situated on part of said lot 1712, on the south by a width of one hundred feet by part of said lot 1712 of the said parish of Saint-Lérusalcm d'Argentcuil belonging to Claire Ricndcau or representatives, and on the width by one hundred feet by part of said lot 1712 of the parish of Saint-Jérusalem d'Argenteuil belonging to the vendor the said Emilien Laurin and on the west by a private road situated on part of the said lot 1712 of the parish of Saint-Jérusalem d'Argentcuil, the whole English measure and more or less.The whole such as it is presently found with its servitudes, active and passive, apparent and occult without restrictions nor reservation on the part of the vendor.Contract No.106270.Municipal taxes: $0.90; catholic school taxes: $32.98; Protestant school taxes: $5.91.Total: $39.79.D.MacRac, R.R.7.Lachute, Québec-Pt.1919 Sainl-Jérusalem d'Argentcuil, deed No.110646.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the parish of Saint-Jérusalem d'Argenteuil, as forming part of lot number one thousand nine hundred and nineteen (Pt.1919) measuring one hundred feet in width in front and approximately one hundred twenty-five fect in reur by a depth of one hundred fect; bounded cast by part of same lot sold to Gilbert Demerse, south by that part of the same lot sold to James Hynes and partly by the residue of the property of the vendor and west by part of same lot sold to Carl Demerse, English men sure.With buildings thereon erected.Municipal taxes: $13.74; school taxes: $35.38.Total: $49.12.Louis I'atalo.539 Dorothy St., Greenfield Park, Québec -Pt.1919, Saint-Jérusalem d'Argenteuil, deed No.95639.A certain piece of hind situated in the parish of Saint-Jérusalem d'Argenteuil, known and designated on the official plan and book of reference of the said parish as being a portion of the lot number one thousand nine hundred and nineteen (Pt.1919) measuring one hundred feet (100') on each side, bounded north by Roy Robertson, cast by G.H.Quinn.south by the road and west by Win.E.Hammond.English measure more or less.As the property now subsists with all the active and passive ser- 1822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, n° 12 actives et passives y attachées.Sans bâtisses.Taxes municipales: $4.82; taxes scolaires: $17.40.Total: $22.22.Mme A.Houle, 4 rue Millway, Lachute, Québec.\u2014Lot 1405-199, Saint-Jérusalem d'Argentcuil.Acte No 101519.Un certain emplacement connu et désigné aux plan et livre dc renvoi officiels de la paroisse tie Saint-Jérusalem d'Argentcuil, comme étant le lot numéro cent quatre-vingt-dix-neuf dc la subdivision officielle du lot originaire numéro mille quatre cent cinq (1405-199).Sans bâtisse.Le tout tel qu'il se trouve actuellement avec les servitudes actives et passives apparentes et occultes, sans restrictions ni réserve dc la part de la venderesse et toute en conformité avec le contrat enregistré sous le No 101519.Sans bâtisse.Taxes municipales: $157.57; taxes scolaires: $17.33.Total: 8174.90.Eugène St.Hclairc, adresse inconnue.\u2014 Lot No pt.1892, Saint-Jérusalem d'Argenteuil.Le 35% ouest d'un lot numéro pt.1892 désignée comme suit: un certain morceau de terre connu et désigné aux plan et livre dc renvoi officiels de la paroisse dc Saint-Jérusalem d'Argentcuil comme étant une partie du lot numéro mille huit cent quatre-ving-douze (pt.1892) mesurant cent pieds de largeur par une profondeur «le cent cinquante pieds (100' x 150') plus ou moins borné au nord et à l'est par le résidu du même lot appartenant au vendeur, au sud par la propriété de M.Jean Landry acquise par acte enregistré sous le numéro 86489, et à l'ouest par le chemin public.Sans bâtisse.Taxes municipales: $0.90; taxes scolaires: $8.52.Total: $9.42.Gérard DeBellefeuille, 244 chemin Bethany, Lachute, Québec\u2014Pt.697.Saint-Jérusalem d'Argenteuil.Acte No 55852.Un certain morceau de terre connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse dc Saint-Jérusalem d'Argentcuil, comme formant purtie du lot numéro six cent quatre-vingt-dix-sept, mesurant soixante pieds dc largeur par cent pieds dc profondeur, le tout mesure anglaise; borné au nord par le vendeur à l'est par le chemin Bétha-nie, au sud par Adélard Patry, et à l'ouest par la propriété de Lem.C.Barron.Tel que le tout se trouve et dont l'acquéreur se déclare satisfait comprenant toutes les servitudes y attachées.Avec bâtisses y érigées.Acte Nos 68083, 68167.Un certain morceau de terre connu et désigné aux plan et livre dc renvoi officiels de la paroisse dc Saint-Jérusalem d'Argenteuil comme étant le lot numéro six cent (.pt.697) mesurant quinze pieds (15') de largeur par cent vingt-deux pieds (122') de profondeur; borné à l'est sur une largeur dc six pieds (6*) par le lot 697-56 ou L.Laurin ou représentants et sur une largeur de neuf pieds (9') par partie non subdivisé dc 697 ou G.DeBellefeuille ou représentants; au nord partie sur une distance dc cent deux pieds (102') par le lot 697-58 et partie sur une distance de vingt pieds (20') par le lot 697-56, au sud par partie non subdivisée dudit lot 697 ou Geo.Patry ou représentants et à l'ouest par la rue Mitchell; et le tout mesure anglaise plus ou moins.Acte No 68083.Un certain morceau de terre connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels dc la paroisse de Saint-Jérusalem d'Argentcuil comme étant la partie du lot numéro (pt.697) mesurant trente pieds de largeur (30') sur le côté ouest, cent vingt-deux pieds (122') dc profondeur du côté nord, cent vingt pieds (120') sur le côté sud et cinquante pieds (50') vitudes thereto attached.Without buildings.Municipal taxes: $4.82; school taxes: $17.10 Total: $22.22.Mrs.A.Houle, 4 Millway St., Lachute, Que.\u2014 Lot 1405-199, St.Jerusalem d'Argenteuil.Deed No.101519.A certain emplacement known and designated on the official plan and hook of reference of the parish of St.Jérusalem d'Argenteuil as being lot number one hundred and ninety-nine of the official subdivision of original lot number one thousand four hundred and live (1405-199).Without a building.The whole such as it is presently found with servitudes, active and passive, apparent or occult, without restriction nor reservation on the part of the vendor and the whole in conformity with the deed registered under No.101519.Without a building.Municipal taxes: $157.57; School taxes: $17.33.Total: $174.90.Eugène St.Hclairc, address unknown.\u2014 l.nt No.Pt 1892, St.Jérusalem d'Argentcuil.35% west of lot number Pt 1892 designated as follows: a certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the parish of St.Jérusalem d'Argentcuil as being a part of lot number one thousand eight hundred and ninety-two (Pt 1892) measuring one hundred feet in width by a depth of one hundred and fifty feet (100' x 150') E.M.more or less bounded on the north and cast by the remainder of the same lot belonging to the vendor, on the south by the property of Mr.Jean Landry acquired by a deed registered under number 80489.ami on the west by the public road.Without buildings.Municipal taxes: $0.90; School taxes: $8.52.Total: $9.42.Gérard DeBellefeuille, 244, chemin Bethany.Lachute, Que \u2014Pt 697 St.Jérusalem d'Argenteuil.Deed No.55852.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the parish of St.Jérusalem d'Argenteuil, as forming part of lot number six hundred and ninety-seven, measuring sixty feet in width by one hundred feet in depth, the whole English measure; bounded on the north by the vendor on the cast by Bcthanie Road, on the south by Adélard Patry, and on the est by the property of Lem.C.Barron.Such as the whole is found and of which the purcliaser is said to he satisfied including all the servitudes attached thereto.With buildings erected thereon.Deed Nos.68083, 68167.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the parish of St.Jerusalem d'Argenteuil, as being lot number six hundred (Pt 697) measuring fifteen feet (15') in width by one hundred and twenty-two fect (122') in depth; bounded on the cast by a width of six feet (6*) by lot 697-56 or L.Laurin or representatives and on a width of nine feet (90 by unsubdivided part of 697 or G.DeBellefeuille or representatives; on the north part by a distance of one hundred and two feet (102') by lot 697-5S and part on a distance of twenty feet (20') by lot 697-56, on the south by an unsubdivided part of said lot 697 or Geo.Patry or representatives and on the west by Mitchell Street; the whole English measure more or less.Deed No.68083.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the parish of St.Jérusalem d'Argenteuil as being part of lot number (Pt.697) measuring thirty feet in width (30') on the west side, one hundred and twenty-two fect (1220 in depth on the north side, one hundred and twenty h el (120') on the south side and fifty feet (51)') QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1909, Vol.101, No.12 1823 sur le côté est et de là du coin sud-est se dirigeant vers l'ouest une distance de vingt (.20) pieds et do là en angle droit vers l'ouest une distance dc (cul pieds (100') jusqu'à la rue Mitchell, borné ii l'ouest par la rue Mitchell à l'est par partie non subdivisé du lot 697 ou G.DeBellefeuille ou représentants au nord par partie non subdivisé du lot 697 ou dame Jessie M.Mitchell ou représentants, au sud par partie non subdivisé du lot No.697 ou R.Lemay ou représentants, le tout mesure anglaise plus ou moins.Taxes municipales: $631.70; taxes scolaires: $570.45.Total: $1,202.15.Donné à Lachute, ce 5ièmc jour du mois de mars, 1969.Conseil municipal du comté d'Argentcuil.Le sccrètaire-Msorier, 28306-1 l-2-o Douglas R.Bradford.Municipalité du comté dc Pontine Avis public est par les présentes donné pur le soussigné, Arthur Labelle, secrétaire-trésorier du conseil du comté de Pontiac, que les terrains ci-après décrits seront vendus à l'enchère publique duns l'édifice du comté, Campbells Bay, Québec, JEUDI, le HUITIÈME jour dc MAI, 1969 à DIX heures dc l'avant-midi, pour les cotisations et frais dus aux municipalités ci-après mentionnées, à moins que lesdites taxes et frais encourus ne soient payées avant le jour fixé |k)iir la vente on the east side and thence from the southeast corner going west a distance of twenty (20) feet and thence at a right angle to the west a distance of one hundred fect (100') up to Mitchell Street, bounded on the west by Mitchell Street, on the cast by an unsubdivided part of lot 697 or G.DeBellefeuille or representatives on the norht by an unsubdivided part of lot 697 or Mrs.Jessie M.Mitchell or representatives, on the south by an unsubdivided part of lot No.697 or R.Lemay or representatives, the whole English measure more or less.Municipal taxes: $631.70; School taxes: $570.45.Total: $1,202.15.Dated at Lachute, Québec this 5th day of March 1969.Municipal Council of the county of Argenteuil.Douglas R.Bradford, 28300-11-2 Secretary-Treasurer.Municipality of the county of Pontiac Public notice is hereby .given by Arthur Lahcllc, Secretary-Treasurer of the municipality of the county of Pontine, that the lands hereinafter mentioned, will be sold by public auction at the county building, Campbells Bav, Québec, on THURSDAY, the EIGHTH day of MAY, 1909, at the hour of TEN' o'clock in the forenoon, for the assessments and costs due the municipalities hereinafter descrilwd, unless they be paid to me with costs incurred, before the day fixed for the sale Municipalité du ennton dc Aldfiold \u2014 Municipality ol the township of Aldficld \t\t\t\tTaxes\tTaxes\t Nom sur rôle\tSuperficie\tLot No\tItullR\tnum.\t¦col.\t \t\t\t\t\t\tTotal Name ou roll\tArea\tLot No.\tItaiiRe\tMun.\tSchool\t \t\t\t\traxes\ttaxes\t \t100 ac.\t\t\tS 4.00\t$ 14.84\tS 18.84 \t100 ac.\t23.\t\t4.00\t14.84\t18.84 \t\t\t\t4.00\t14.84\t18.84 \t100 nc.\t\tK.\t4.00\t14.84\t18.84 \t\tP.34 8.\t1.\tÎI.50\t83.07\t103 47 \t125' x 1150'.\tP.34 S.\t1.\t8.00\t00.17\t08 17 \tHat .-rill.-Hide\t\t\t\t\t \t\t\t7.\t38.50\t79.07\t117.67 Ulwlle, André.\tBat.scuI.-BMr\t\t\t\t\t \t\t15.\t7.\t45 00\t103.88\t148 88 \tUfit.seul.-BMR\t\t\t\t\t \t\t\t7.\t37 50\t107 01\t145.11 Labette, Gérald.\tBat.scuI.-BMr\t\t\t\t\t \t\t14.\t7.\t52.60\t103.88\t150.38 \t14 ac.\tP.2.\t8.\t10.00\t83.02\t09.02 \t100 11c.\t\t5.\t4.00\t10.1G\t31.10 \t\t\t\t\t\t Municipalité du canton de Allcyu \u2014 Municipality of the township of Alloyn\t\t\t\t\t\t Gibson, John.\t240'x 180'.\tP.0-A.\t2.\tt 11.81)\tS 13.55\tS 25.44 \t\t\t\t\t\t Municipalité du canton dc l'Ile Allumette Est Municipality of the townsliip of Allumette Island Kant Rurale, Frank.1 1 uidctte.Alfio.McCool, .1.1 me.100 ae.10 ac.17 ac.87 uc.40 ac.!.Coin-corner n.e.-n.w.4.He-Island 28.Ilo-Island 20.He-Island 30.4.S 11 90\t 7.81\tS 20 77 22 09\t43.12 Municipalité du cant\ton do Grand Calui\tnet \u2014 Municipal!)\t¦ of the towns\tlip of Cin\tnd t .dun\tct ll'-rard, Léon.\t>* ac.\tP.\" 18F.\t\tS 30.00\t$ 03.84\t$ 1311 Ml 1S24 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, n\" 12 Municipalité du canton do Leslie \u2014 Municipality of the township of Leslie Nom sur rôle Name on roll i Uniinau.Kaye C.Crawford, James.Crawford, James.Crawford, James.Crawford, James.Francoeur, Fred Jr.Crnndmnison, Mine-Mrs.Hazel.Guénette.Maurice.Lance, Adrien.Lance, Adrien.Lance, Adrien.Lance.Adrien.Lacroix, Isaac.Laflqur, F.-Mmo-Mra.Taylor.St.Aubin, Omer.Superficie Area 100 ac.100 no.100 ac.100 ac.82 ac.420' x 210'.210' x210'.38 ac.41 ac.35 ac.59 ac.100 ac.app.M ac.app.\\i ac Lot No Lot No.\tRang 1 tango\tTaxes mun.Mun.raxes\tTaxes scol.School taxes P.21 70 LCH.42.7.\t\t\t$ 20.31 11.04 11.04 23.28 23.30 20.31 \t\tS 3.07 3.68 8.19 8.20 8.43 21.84\t 43.\t\t\t 43 .\t3.\t\t 44.\t\t\t \t\t\t 1>.18.\tA.\t\t P, 18.\t\t\t73.01 14.74 14.74 7.30 7.37 55.87 155.20 00.92 S.P.22.\t\t5.30 5.30 2.08 2.07 10.10 25.97 9.18\t \t\t\t S.P.24.\t5.\t\t S.P.25.\t\t\t \t\t\t P.31-A.P.32.\t2.2.\t\t \t\t\t Municipalité du canton de Bristol \u2014 Municipality of the township of Bristol Taylor, succ-est.E.Hex.| 4-A-l.1 $10.10 S 8.25 S 24.35 Chalet et lot avec droit dc passage 4-A-3.Smith Kenneth Harold tl al.48 lota.Cottage and lot with right of way 4-A-3.10-98 a-to 101.10-123 i\\-to 140 10-142 Mo 152 10-155 Mo 157 10-101 Mo 104 10-74-9 Mo 14 10-74-48 et-nnd 49 10-75 Excepté partie appartenant :\\ l'Église Presbyterian.Except part belonging to Presbyterian Church.10-70 Kxccpté partie appartenant a James Adc.Except part belonging to James Adc.10-A.130.11 480.11 022.2 Excepté partie appartenant :\\ Norway Bay Corp.Except part belonging to Norway Bay Mun.Corp.Mun.Municipalité du village de Campbells Bay \u2014 Municipality of the village of Campbells Bay \tBat.scul.-Bldgs\t\t\t\t$ 38.40\t\t \t\tP.1.\t\t$ 90.50\t\t8\t134 9(1 372 'J'.i \t54' x 75'.\t\t\t190.29\t192.00\t\t ICcoii.Mnie-Mrti.Pcior\t\t158.\t\t91.01 189.75\t138.80 102.00\t\t2'JS 11 381.75 \t\tP.137.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Municipalité du canton de Chichester \u2014 Municipality of the township of Chichester Lépinc, succ-est.Win.\t\tPts 21, 22.\t2\t1\t \t\tP.o.-w.21-C\t\t8 32.00 1*142.07\tS 171 i Sud-ouest coin lot 21-C borné au nord et à l'est par le chemin municipal.Southwest corner lot 21-C bounded on north ami \"a ilie cast by municipal road.Floury, succ-est.Mme-Mrs.John.I ^ac.I P.21-A.1.49.50 140.78 11)0.28 Borné au sud par la propriété de Cecil Venue et Bounded by property of Cecil Vcnno on south :ci\"l punie 21-A rang 1; à l'ouest par le chemin entre les part 21-A range 1; on the west by the sido road between lots 21-A, 22, rang 1 ; au nord et ft l'est par balance du the lots 21-A nnd 22.range 1 ; on the north ami on the lot 21-A, rang 1.cast by remainder of lot 21-A, range 1.Municipalité du village de Chapeau \u2014 Municipality of the village of Chapeau \t\tP.77.78-A\t\tS 3.08 35.83\t$ 18.90 197.80\t$ 22 .iS 233.00 Marcotte, Arthur.\tapp.1/5 ac.\t154-C.P.155.\t\t\t\t Municipalité dc Iluildcrsficld \u2014 Municipality of Huddcrsficld\t\t\t\t\t\t ( ¦ i in bier, Dillon\t\t10-A.\t8.\tS 3 71\t$ 22.88 |$ 21 i\t \t\t\t\t\t\t QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1825 Municipalité du canton do l'Ile Allumette \u2014 Municipality of the township of Allumette Island Nom sur rôlo Name on roll\tSuperficie Area\tLot No Lot No.\tKang Itango\tTaxes mun.Mun.raxes\tTaxes scol.School taxes\tTotal \tapp.50 at*.\tE.1'.30-A.\t4.\t$008.42 83.40 55.45 24.06\t$ 53.60 208.84 50.70 37.80\t$ 752.08 382.30 112.15 02.76 \t\tP.20.\t2.\t\t\t \tapp.100 ac.\t21.\t3.e.\t\t\t Yaillancourt, Mcdéric\t\t37-A.\t4.\t\t\t \tapp.Mac-\tP.33-A.\t5.\t\t\t Municipalité do Clapham \u2014 Municipality of Clnpham Lcpaek, Prank.Lcnnok, Frank.Lopnclc, Frank.Lafleur.Charles.IWb, Frank.Paris, Frank.Si.Aubin, Oinor.Si.Aubin, Oinor.Ilivet.Mmo-Mrs.Laurent.100 ac.\t36.\t2 60 ne.\t36-B.\t2 \t37-B.\t2 100 ac.\t42.\t1 \t17.\t1 \t14-C.\t2 150 ac.\t10-A, 17-B.\t2 100 no.\t10.\t1 \tP.12-B.\t4.\t\t 7.35 3.08 35 04 7.42 39.17 3.08 59.80 3.71 $ 11.78 5.89 35.30 49.03 212.03 22.05 80.84 Municipalité du ennton do Litchfield \u2014 Municipality of the township of Litchfield Hi\".7.11 IT.Fred.\t60 ac.110 ac.\tP 21-B.\t11.11.\t$ 30.00 40.44\t$ 64.32 128.18\t$ 84.38 108.62 \t\t\t\t\t\t Municipalité du canton do Onslow Nord \u2014 Municipality of the township of Onslow North\t\t\t\t\t\t o'Ounncll Léo et al.\t\t\t8.\t$ 80.10 8.25\t\t$ 80,10 8.26 \t1 uc.\t2, P.A.\t8.\t\t\t \t\t\t\t\t\t Municipalité du canton do Onslow Sud \u2014 Municipality of the townsliip of Onslow South\t\t\t\t\t\t Smith, succ-est.H.-I.I'nntlx, Poler John.\t100 ne.\t1-A.1-B.1-C.11-A.\t0.G.\t$197.30 101.70 20.00\t$328.92\t$ 520.20 101.79 20.(K) Stundon, Basil.\t\tN.P.3-A.\t6.\t\t\t \t\t\t\t\t\t Municipalité du village de (Juyon \u2014 Municipality of the village of Quyon\t\t\t\t\t\t lluoett, Itonnld.\t\t89, 90.\t\t$ 5.83 GO 09\t$ 18.01 57.85\tS 23.84 117.94 Si.I'icrro Albert.\t11,418 p.c.-sci.-ft.\t71.\t3.\t\t\t \t\t\t\t\t\t Municipalité du village de Portage du Fort \u2014 Municipality of the village of Portage du Fort l.lliolt, Wilfrid.ilauthier, Lionel.Clnuthlor, Lionel.ioiilhior, Lionel.i lauthier, Lionel.1 lauthier, Lionel.' miiibier.Lionel.Gnuthior, Lionel.Tiinguny, succ-est., Mine-Mrs.Juno.Taiiauiiy, succ-est.Mine-Mrs.Jane.Tourangeau, Raphael (Motel).187.24.140-8.140-9.140-10.140-11.140-12.140-13.140-14 140-15.8.2.P.152 Rue Mill St Chem.Calumet Rd Chém.Calumet Rd Chem.Calumet Rd.Chem.Calumet Rd.Chem.Calumet Rd.Chem.Calumet Rd Rue Craig St.line Craig St.< 'bent.Clarendon ltd $ 4.20 80.31 13.20 13.20 810.03 13 20 13.20 13 20 28 is 12 m 8 04.11) 7.37 46 04 5S0.28 7 37 7.37 7.37 33 42 S.20 1S20 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 19G9, 101' année, n° 12 Municipalité du cnnton do Thorno \u2014 Municipality of the township of Thorno Nom sur rôle Nu mo on roll\tSuperficie Area\tLot No Lot No.\tRang Range\tTaxes mun.Mun.raxes\tTaxcs scol.School taxes\tTotal S 40.40 \tBût.seul.-Bldg\t67.\t2.\tS 23.13\tS 20.30\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Municipalité du cnnton do Bryson \u2014 Municipality of the township of Bryson\t\t\t\t\t\t Lachnnco, Mondoza.\t\t\tGreen Lake.\t% 10.90\t\t$ 10.00 \t\t\t\t\t\t Donné à Waltham, Québec, le 3 mars 1969.Le secrétaire-trésorier, 28307-1 l-2-o Arthuu Labelle.Given at Waltham, Québec, March 3, 1969.Arthur Labelle, 28307-1 l-2-o Secretary-Treasurer.Arrêtés en Conseil Orders in Council Arrêté en conseil Chambre du Conseil Executif Numéro 604 Québec, le 5 mars 1969.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation du droit de prélèvement du Comité paritaire du Bois Ouvré de Québec.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail et de la Main-d'œuvre: Que le droit de prélèvement du Comité paritaire du Bois Ouvré de Québec, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 3354 du 16 octobre 1968, soit prolongé jusqu'au 30 juin 1969, aux mêmes taux et conditions.Le greffier du Conseil executif, 28401-o Jacques Pré.mont.Arrêté en conseU Chambre du Conseil Executif Numéro 603 Québec, le 5 mars 1969.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie du camionnage dans la région de Montréal.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi des décrets dc convention collective (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 143), le ministre du Travail et de la Màin-d'oeuvre a donné avis, à la suite dc requêtes qui lui ont été présentées, de son intention de soumettre à i'appréciation et A la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications au décret 913 du 16 juin 1968 et modifications, relatif à l'industrie du camionnage dans la région dc Montréal; Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle du Québec, édition du 9 novembre 1968; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément A la Loi; Order in Council Executive Council Chamber Number 604 Québec, March 5, 1969.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the extension of the right to levy of the Comité paritaire du Bois Ouvré de Québec.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour and Manpower: That the right to levy of le Comité paritaire du Bois Ouvré de Québec (authorized by a by-law approved by Order in Council number 31151, dated October 16, 1968), be extended until June 30, 1969, at the same rates and under the same conditions.Jacques Prémoxt.28401-o Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 603 Québec, March 5, 1969.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments to the decree respecting the Cartage Industry in the Montreal Region.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964* c.143), the Minister of Labour and Manpower gave notice that, as a result of petitions received, he intended submitting certain amendments to Decree number 913 of June 16,1968, as amended (Cartage Industry in the Montreal region) to the Lieutenant-Governor in Council, for consideration and decision; Whereas the notice was published in ll« Québec Official Gazette of November 9, 196S; Whereas, in compliance with the Act, i he objections brought forth were duly considered: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1827 Ii, est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que ledit décret, numéro 913, soit modifié comme suit: 1° Le nouvel article 2.05 suivant est ajouté: \u2022¦ 2.05 Le présent décret ne s'applique pas aux employeurs et aux artisans de Candiac, Laprairie, Delson, Côte-Saintc-Cathcrine et Saint-Constant, ni à leurs salariés, excepté s'ils l'xploitcnt, avec ou sans permis de la Régie des Transports, un service local à l'intérieur de l'Ile de Montréal.» 2° A l'article 5.04, le mot « consécutives » est ajouté après les mots « a droit a une indemnité minimale égale à quatre (4) heures».3° Le nouvel article 5.14 suivant est ajouté: « 5.14 Dispositions particulières concernant l'en-lèvemenl des ordures: Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux employeurs, artisans et salariés affectés à ce genre de travail: n) Semaine normale de travail: La semaine normale dc travail est au maximum de quarante-huit (48) heures, réparties sur cinq (5) jours, du lundi au vendredi inclusivement.b) Journée normale de travail: Une journée normale de travail est au maximum de douze (12) heures.c) Heures supplémentaires: Le travail exécuté eu plus dc douze (12) heures par jour ou de quarante-huit (48) heures au cours d'une même semaine, doit être rémunéré au taux normal majoré de cinquante pour cent (50%).d) Samedi: Tout travail exécuté le samedi doit être rémunéré au taux normal majoré de cinquante pour cent (50%).c) Dimanche: Tout travail exécuté le dimanche doit être rémunéré au taux normal majoré de cent pour cent (100%)./) Jours fériés: Tout travail exécuté un des jours fériés mentionnés à l'article 9 autre que Noël et le premier jour de l'An, doit être rémunéré au taux normal majoré de cent pour cent (100%).» Ia! greffier du Conseil exécutif, 2S401-o Jacques Prémont.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 601 Québec, le 5 mars 1969.Présent; Le Lieutenant-gouverneur en conseil.< o.n'cehnant des modifications au décret relatif au commerce de l'alimentation au détail dans la région de Sherbrooke.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective 'Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 143), les parties contractantes à la convention collective de travail relative au commerce de l'alimentation au détail dans la région de Sherbrooke, rendue obligatoire par le décret numéro 20 du 5 janvier 1955 et modifications, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une nquête à l'effet de soumettre a l'appréciation cl à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle du Québec, édition du 18 janvier 1969; Therefore, it is ordered upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour and Manpower: That said Decree number 913 be amended as follows: 1.The following new section 2.05 is added: \"2.05 The present decree does not cover employers and artisans in Candiac, Laprairie, Delson, Côte Sainte Catherine and Saint Constant, nor the employees thereof, unless they operate a local service within the Island of Montreal, with or without a permit from the Transportation Board.\" 2.In section 5.04, the word \"consecutive\" is added before the words \"hours' pay\".3.The following new section 5.14 is added: \"5.14 Special provisions governing garbage removal: The following special provisions govern employers, artisans and employees engaged in such work: (a) Standard work week: Standard hours of work shall not exceed forty-eight (48) a week, scheduled over five (5) working days, Monday through Friday.(6) Standard work day: Standard hours of work shall not exceed twelve (12) a day.(c) Overtime: Time and one half shall be paid for all work performed over and above twelve (12) hours a day or forty-eight (48) in any given week.(d) Saturdays: Time and a half shall be paid for all work performed on Saturdays.(e) Sundays: Double time shall be paid for all work performed on Sundays.(/) General holidays: Except for Christmas Day and New Year's Day, double time shall be paid for all work performed on any of the general holidays listed in section 9:00.\" Jacques Prémont, 28401-o Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 601 Québec, March 5, 1969.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments to the decree respecting the Food Products Retail Trade in the Sherbrooke region.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.143), the contracting parties to the collective labour agreement respecting the Food Products Retail Trade in the Sherbrooke region (made binding by Decree number 20 of January 5,1955, as amended) have petitioned the Minister of Labour and Manpower to submit certain amendments to the said decree, to the Lieutenant-Governor in Council for consideration and decision; Whereas the petition was published in the Quebec Official Gazette of January 18, 1969; 1828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1909, 101' année, u° 12 Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la Loi; Il est oh donné, en conséquence, sur la proposition «le l'honorable ministre du Travail et de la Main d'oeuvre: Que ledit décret, numéro 20, soit modifié comme suit: 1° Le paragraphe «a» dc l'article III est remplacé par le suivant: « a) Ia semaine normale de travail est de quarante-trois (43) heures réparties selon l'ho-rnirc suivant: Lundi: jour chômé; mardi : dc 8 h.30 à 17h.30; mercredi: de 8h.30 à 17h.30; jeudi: de 8h.30 il 18h.: vendredi: de 8h.30 à 211».30; samedi: de Bh.30 A 17h.» 2° Le paragraphe « a » de l'article IV est remplacé pnr le suivant: « IV.Taux des salaires minimaux: a) Les taux des salaires minimaux sont les suivants: Taux Classification des emplois: hebdomadaire Moucher et acheteur.$90 Moucher.72 Moucher il l'embauchage.55 Moucher après six mois.60 Moucher après 12 mois.63 Commis préposé aux légumes ù l'embauchage .57 Commis préposé aux légumes après 12 mois.65 Commis préposé aux légumes après 24 mois.70 Commis préposé aux légumes après 36 mois.80 Premier commis épicier ou commis en chef.80 Commis épicier sans expérience.50 Commis épicier après 6 mois.55 Commis épicier après 12 mois.60 Commis épicier après 18 mois.65 Commis livreur avec camion il l'embauchage 60 < 'on i n i is livreur avec camion après six mois.65 Commis livreur avec camion, après 12 mois.72 Messager-emballeur \u2014 aide-livreur à bicyclette.$1.15 l'heure Caissière, à l'embauchage.50 Caissière, après six mois.53 Caissière, après 12 mois.58 Lors dc la mise en vigueur du présent décret et pendant toute sa durée, les taux de salaires qui y sont rendus obligatoires, ne doivent pas être inférieurs à ceux déterminés par la Loi du salaire minimum.Advenant le cas de taux de salaires inférieurs, ils sont automatiquement majorés ik ceux fixés par la Loi dc salaire minimum.» 3° Les paragraphes « a » et « b » de l'article V sont remplacés par les suivants: « V.Jours fériés, chômés et payés: a) Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés: Le jour de l'An, le 2 janvier, la Saint-.Tcan-Muptiste, la fête de la Confédération, la fête du Travail, le jour de Noël et le 20 décembre.b) Les lundis de la semaine de Noël et du Nouvel-An sont des jours ouvrables, toutefois ces deux lundis sont payés au prorata de la semaine payée en plus du salaire habituel hebdomadaire.» 4° Les paragraphes « a » « b » et « c » de l'article VI sont remplacés par les suivants: WiiEUEAS, in compliance with the Act, the objection brought forth was duly considered; Therefore, it is ordered upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour and Manpower: That said Decree number 20 be amended as follows: 1.Subsection \"a\" of section III is superseded by the following: \"(a) The 43-hour standard work week shall be scheduled as follows : Monday: non-working day; Tuesday: 8:30 a.m.to 5:30 p.m.; Wednesday: 8:30 a.m.to 5:30 p.m.; Thursday: 8:30 a.m.to 6:00 p.m.; Friday: 8:30 a.m.to 9:30 p.m.; Saturday: 8:30 a.m.to 5:00 p.m.\" 2.Subsection \"a\" of section IV is replaced by the following: \"IV.Minimum wage rate: (a) Minimum wage rotes are as follows: Weekly Classifications: rales Butcher and buyer.890 Butcher.72 Mutchcr: hiring rate.55 Mutchcr: after 6 montlis.00 Mutcher: after 12 months.03 Produce clerk: hiring rate.57 Produce clerk: after 12 months.05 Produce clerk: after 24 montlis.70 Produce clerk: after 36 months.SO Head grocery clerk.80 Grocery clcrK: no experience.50 Grocery clerk: after 6 months.55 Grocery clerk: after 12 months.00 Grocery clerk: after 18 months.05 Deliveryraan (with truck): hiring rate.00 after 0 months.05 after 12 months.72 Messenger, wrapper, delivery boy (with bicycle).$1.15 on hour Cashier: hiring rate.50 Cashier : after 6 months.53 Cashier: after 12 months.5S From the effective date of this decree and throughout its term, the wage rates that are hereby made mandatory must not be lower than those stipulated in the Minimum Wage Act.Should they be lower, they shall automatically be adjusted up to those set forth in the aforementioned Act.\" 3.Subsections \"a\" and \"b\" of section V ore superseded by the following: \"V.General holidays with pay: (a) The following arc general holidays with pay: New Year's Day, January 2nd, Saint John the Baptist Day, Canada Day, Labour Day, Christmas Day, December 26th.(b) Mondays in Christmas and New Year's weeks arc working days.Payment for such days shall be in proportion to the employees weekly rate and in addition to his usual weekly salary.\" 4.Subsections \"a\", \"b\" and \"c\" of section VI arc replaced by the following: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1829 « VI.Congés payés: u) Un employé qui a moins de un an de service chez son employeur et qui quitte son emploi durant l'année, a droit à une indemnité égale à 4% du salaire gagné.Celui qui travaille encore à.la date des congés a le choix entre l'indemnité ci-dessus et un jour de congé payé pour chaque mois ou partie de mois pendant lequel il a été au service du môme employeur.b) Tout employé ayant été au service du même employeur pendant un an ou plus a droit à deux semaines dc congé et à une indemnité de congé égale à 4% du salaire.r) Tout employé ayant été au service du même employeur pendant dix ans ou plus a droit à trois semaines de congé et à une indemnité de congé égale à 6% du salaire.Toutefois, la troisième semaine de congé soit être prise à une date fixée par entente entre l'employeur et l'intéressé.» f>° L'article VIII-A est remplacé par le suivant: « VIII-A Congés spéciaux: Tout employé peut bénéficier d'un congé sans perte de salaire dans les cas suivants: Lors de son mariage, du mariage d'un enfant, d'une soeur, d'un frère, du beau-frère, de la hellc-soeur: le jour du mariage.Ijors du décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant: quatre jours.l.ors du décès du beau-père, de la belle-mère: un jour.Lors du décès de la belle-soeur, du beau-frère, du frère ou de la soeur: un jour.» 0° L'article IX est remplacé par le suivant: « IX.Durée du décret: Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec et demeure en vigueur jusqu'au 14 octo-hrc 1971.Il se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une ou l'autre des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit de son intention d'y mettre fin, dans un délai d'au plus soixante (60) et d'au moins trente (30) jours avant l'expiration originale ou db toute année subséquente.Un tel avis doit également être adressé nu ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre.» IjC greffier du Conseil exécutif, 2S40I-o Jacques Prémont.Arrêté eu conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 602 Québec, le 5 mars 1909.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des modifications au décret relatif ù la fabrication des cercueils dans le Québec.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 143), les parties contractantes à la convention collective de travail relative à la fabrication des cercueuils dans le Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 101 du 31 janvier 1957 et modifications, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et a la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; \"VI.Vacations with pay: (a) Any employee with less than one year's service with an employer who quits the latter's service during the year is entitled to 4% of wages earned.Employees who are still in the employer's service at vacation time are entitled to either 4% of wages earned or a one-day's vacation with pay for each month or part thereof worked in the same employer's service.(b) Every employee with one year's service or more with a same employer is entitled to two weeks' vacation and to vacation pay equal to 4% of cages earned.(c) Every employee with ten (10) years' service or more with a same employer is entitled to three weeks' vacation and to vacation pay equal to 6% of wages earned.However, the third week's vacation shall be taken at a time agreed upon by both employer and employee.\" 5.Section VHI-A is superseded by the following: \"VHI-A Special leave: Every employee is entitled to special leave with pay in the following instances: one day: on his wedding day, the wedding day of his child, sister, brother, brother-in-law, sister-in-law; four days: on the death of his father, mother, spouse or child; one day: on the death of his father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, brother or sister.\" 6.Section IX is replaced by the following: \"IX.Term of the decree: This decree becomes effective on the day it is published in the Québec Official Gazelle and remains in force until October 14,1971.It automatically renews itself from year to year thereafter unless one of the contracting parties gives the other a written notice to the contrary, no more than sixty (60) and no less than thirty (30) days prior to its original expiry date or any subsequent year.Such notice shall also be filed with the Minister of Labour and Manpower.\" Jacques Fremont, 28401 -o Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 602 Québec, March 5, 1969.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments to the decree respecting the Casket Manufacturing in Québec.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.143), the contracting parties to the collective labour agreement respecting the Casket Manufacturing in Québec (made binding by Decree number 101 of January 31, 1957, as amended) have petitioned the Minister of Labour and Manpower to submit certain amendments to the said decree to the Lieutenant-Governor iu Council, for consideration and decision; 1830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, n\" 12 Attendu que Indite requête a été publiée dans la Gazette officielle du Québec, édition du 21 décembre 1968; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition dc l'honorable ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que ledit décret, numéro 101, soit modifié comme suit: 1\" Le paragraphe « a » dc l'article III (Taux minimaux dc salaires) est remplacé par le suivant: « III.Taux minimaux de salaires: a) Les taux minimaux dc salaires des salariés, y compris les salariés du sexe féminin, travaillant il la fabrication des cercueils, définie dnns le champ d'application industriel du présent décret, de même que ceux des chauffeurs dc chaudières, des gardiens chauffeurs de chaudières, des conducteurs dc machines fixes, des gardiens, des préposés i\\ l'expédition; des préposés nu transport, à l'entretien ou a la réparation des machines, des immeubles, sont les suivants: Zone I: Le salaire moyen doit être d'au moins 81.80 l'heure.Pour établir le salaire moyen, on divise le montant global des salaires gagnés par tous les salariés que vise le présent décret, par le chiffre total des heures de travail effectuées.Cependant, il faut exclure du montant global des salaires gagnés les montants versés à titre dc majorations pour heures supplémentaires de même que les salaires touchés par les personnes qui occupent un emploi de contremaître ou un poste supérieur ù celui de contremaître.Taux horaires minimaux 1er semestre.81.30 2e semestre.1.35 Après un an.1.40 Après deux ans.1.45 Les salaires minimaux suivants s'appliquent aux chefs-conducteurs dc 4c classe, aux gardiens et aux gardiens-chauffeurs seulement: lrc année.81.35 Après un an.1.40 Zone II: Le salaire moyen doit être d'au moins $1.65 l'heure.Pour établir le salaire moyen, on divise le montant global des salaires gagnés par tous les salariés que vise le présent décret, par le chiffre total des heures de travail effectuées.Cependant, il faut exclure du montant global des salaires gagnés les montants versés à titre de majorations pour heures supplémentaires de même que les salaires touchés par les personnes qui occupent un emploi de contremaître ou un poste supérieur à celui de contremaître.Taux horaires minimaux 1er semestre.SI.20 2e semestre.1.25 Après un an.1.30 Après deux ans.1.35 Whereas the petition was published in the Québec Official Gazelle of December 21, 196S; Whereas no objection was brought forth against the approval of the proposed amendments; Therefore, it is ordered upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour and Manpower; That Decree number 101 be amended as follows: 1.Subsection \"o\" of section ni (Minimum Wage Rates) is replaced by the following: \"ID.Minimum Wage Rales: (a) Minimum wage rates for male and female employees engaged in the manufacturing of caskets, as defined in the industrial jurisdiction of this decree, as well as those of boiler firemen, watchmen-firemen, stationary enginemcn, watchmen and men whose work consists in the shipping, transportation, maintenance or repair of machines and buildings, shall be as follows: Zone I: The average wage rate must be at least 81.80 an hour.To arrive at the average wage, the total earnings for all employees governed by this decree arc divided by the total hours worked.However, the following are not included in the total earnings: overtime paid; wages of any person holding a position of foreman or nbove that of foreman.Minimum hourly rates First six montlis.81.30 Second six months.1.35 After 1 year.1.40 After 2 years.1.45 The following minimum rates apply to chief stationary enginemen (4th class), watchmen-firemen and watchmen only: First year.81.35 After 1 year.1.40 Zone II: The average wage rate must be at.least 81.65 an hour.To arrive at the average wage, the total earnings of all employees governed by the decree are divided by the total hours worked.However, the following arc not.included in the total earnings: overtime paid: wages of any person holding a position of foreman that of foreman.Minimum hourly rale* First six months.$1.20 Second six montlis.1.25 After 1 year.1.30 After 2 years.1.35 Les salaires minimaux suivants s'appliquent aux chefs-conducteurs de 4e classe, aux gardiens et aux gardiens-chauffeurs seulement: The following minimum wage rates apply to chief stationary enginemcn (4th class), watchmen-firemen, and watchmen only: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1831 Taux horaires minimaux I rc année.$1.25 Après un an.1.30» 2° Les paragraphes «a», « g » et «i> dc l'article X (Congé payé annuel) sont remplacés par les suivants: « N.Congé payé annuel: a) Droit au congé: Tout salarié a droit: 1.S'il n'a pas une (1) année dc service continu chez sou employeur, à un congé annuel continu dont la durée est déterminée à raison d'un (1) jour par mois dc travail, sans que la durée du congé exigible excède deux (2) semaines.2.S'il a une (1) année ou plus de service continu chez son employeur, à un congé payé annuel continu de deux (2) semaines.3.L'indemnité afférente au congé est égale i\\ quatre pour cent (4%) du salaire brut gagné par le salarié au cours dc la période de référence.\u2022I.Congé obligatoire: Il est interdit à un employeur dc remplacer par une indemnité compensatrice le congé payé annuel prescrit aux sous-paragraphes 1 et 2, sauf dans le cas dc la deuxième semaine, s'il y a entente entre l'employeur et l'intéressé, g) Période de prise du congé: Chaque congé doit être pria dans les douze (12) mois qui suivent la fin do l'année dc référence.i) Résiliation du contrai dc travail: Lors dc la résiliation de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité représentant quatre pour cent (4%) du salaire gagné depuis le 1er mai précédant la date dc son départ.» Le greffier du Conseil exécutif, 28401-o Jacques Prémont.Order in Council Executive Council Chamber Numéro 600 Québec, le 5 mars 1969.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation du décret relatif à l'industrie du bois ouvré dans In région dc (Juébec.II.est ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail et de la Main-d'œuvre: Que, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 143), le décret numéro 2684 du 28 septembre 1967 et modification, relatif à l'industrie du bois ouvré dans la région de Québec, soit prolongé jusqu'au 3(1 juin 1969.Le greffier du Conseil exécutif, 28401m) Jacques Prémont.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 681 Québec, le 12 mars 1969.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les règlements édictés par la llégic des marchés agricoles du Québec en vertu de l'article 9 de la Loi des produits laitiers.Attendu que l'article 9 de la Loi des produits laitiers (Statuts Refondus 1964, c.121), remplacé par l'article 1 du chapitre 45 du volume des statuts 1906-1967, autorise la Régie des marchés Minimum hourly rates First year.$1.25 After 1 year.1.30\" 2.Subsections \"a\", \"g\" and \"t\" of section X (Vacation with pay) arc replaced by the following: \"X.Annual vacation with pay: (a) Vacation entitlement: Every employee is entitled to: 1.one (1) day's vacation with pay annually for each month worked, up to a maximum of two (2) weeks, if he has less than one (1) year's continuous service with his employer; 2.two (2) weeks* continuous vacation annually if he has one (1) year's service or more with his employer.3.Vacation pay equals four per cent (4%) of total wages earned by the employee during the qualifying period.4.Compulsory vacation: No employer may replace the annual vacation with pay stipulated in paragraphs 1 and 2 above by a monetary compensation.However, employer and employee may agree upon a monetary compensation for the second week's vacation.(g) Timing of vacations: Vacations shall be taken within twelve (12) months of the end of the qualifying period.(i) Cancellation of work contract: When his work contract is cancelled, the employee is entitled to be paid the equivalent of four per cent (4%) of wages earned since May 1st prior to the separation date.\" Jacques Prémont, 28401-o Clerk of the Executive Council.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Number 600 Québec, March 5, 1969.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the extension of the decree respecting the Woodworking Industry in the Québec City region.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour and Manpower: That, pursuant to the provision of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.143), Decree number 2684 of September 28, 1967, as amended (Woodworking Industry in the Québec Citv region) be extended until June 30, 1969.Jacques Prémont, 28401-o Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 681 Québec.March 12, 1969.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning regulations enacted by the Québec Agricultural Marketing Board by authority of section 9 of the Dairy Products Act.Whereas section 9 of the Dairy Products Act (Revised Statutes 1964, chapter 121), replaced by section 1 of chapter 45 of the 1966-1967 Statutes, authorized the Québec Agricultural Marketing 1832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, n\" 12 agricoles du Québec à faire les règlements qu'elle juge nécessaires ù l'application dc l'article 8 de ladite loi, relatif à la délivrance de polices dc garantie aux marchands dc lait, pour assurer le paiement des sommes qu'ils doivent ou pourront devoir à leurs producteurs-fournisseurs ou aux organismes chargés d'appliquer un plan conjoint de producteurs-fournisseurs établi en vertu de la Loi des marchés agricoles (Statuts Refondus, 1964, chapitre 120); Attendu que ladite Régie a adopté les règlements dont le texte ci-joint; Attendu que lesdits règlements doivent être soumis nu surintendant des assurances et n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que ces règlements ont été soumis au surintendant des assurances qui déclare, par lettre du 28 février 1969 qu'ils sont satisfaisants et qu'il n'a pas objection à en recommander l'approbation; Attendu Qu'il est opportun d'approuver lesdits règlements; En conséquence, il est ordonné, sur la proposition du Ministre dc l'agriculture et dc la colonisation: Que sous l'autorité dc l'article 9 de la Loi des produits laitiers (Statuts Refondus 1964, chapitre 121), remplacé par l'article 1 du chapitre 45 du volume des statuts, 1966-1967, soient approuvés les règlements dc la Régie des marchés agricoles du Québec, en date du 5 février 1969, dont le texte ci-joint, intitulé « Règlements faits en vertu dc l'article 9 de la Loi des produits laitiers *.Copie conforme.I.c greffier du Conseil exécutif, Jacques Prémont.REGIE DES MARCHÉS AGRICOLES DU QUÉBEC Prenez avis que le 5 février 1969, la Régie des marchés agricoles du Québec a adopté le règlement ci-après: Règlements faits en vertu de l'article 9 de la Lui des produits laitiers (S.R.Q.1964, Chap.121, amendé par 15-16 Eliz.II, ehap.45) 1.Une police de garantie est délivrée par la Régie des marchés agricoles du Québec au marchand de lait, détenteur d'un permis de la Régie, qui satisfait aux conditions ci-après.2.Chaque année, le marchand dc lait doit, dans les 90 jours qui suivent la date de la fin de son exercice financier, faire parvenir il la Régie une copie dc l'état financier de cet exercice comportant, entre autres, le bilan annuel apuré, les comptes dc profits et in-rtes, d'amortissement et dc capital.3.La Régie peut, aux fins d'établir à sa satisfaction la solvabilité du marchand dc lait, en exiger tous autres renseignements qu'elle estime utiles.4.Si la Régie n'est pas satisfaite dc la solvabilité d'un marchand de lait, elle peut exiger dc celui-ci d'autres conditions qu'elle juge nécessaires Ijour assurer le paiement du lait et de la crème livré à ce marchand de lait par les producteurs-fournisseurs.5.Le marchand dc lait doit également, avant le 1er mars de chaque année, informer la Régie du mode de paiement convenu entre lui et ses Board to make regulations which it deems necessary for the application of section 8 ol the said Act, relative to the issuing of guarantee policies to milk dealers to ensure pa.vm.-nt of sums which they owe or may owe to their producer-suppliers or to bodies charged with applying a joint plan of producer-suppliers established under the Agricultural Marketing Act (Revised Statutes, 1964, chapter 120); Whereas the said Board has adopted the regulations, a copy of which is hereto appended; Whereas the said regulations must be .submitted to the Superintendent of Insurance and will not come into force until they have been approved by the Lieutenant-Governor in Council; Whereas the said regulations have been submitted to the Superintendent of Insurance who declares, by letter of February 28, 1969, that the said regulations are satisfactory and that he has no objection to recommending their approval; Whereas it is expedient that the said regulations be approved; Consequently, it is ordained upon the recommendation of the Minister of Agriculture and Colonization : That, by virtue of section 9 of the Dairy Products Act (Revised Statutes, 1964, chapter 121) replaced by section 1 of chapter 45 of the 1066-1967 Statutes, the regulations entitled \"Regulations enacted by authority of section 9 of the Dairy Products Act\", dated February 5, 1969, a copy of which is hereto appended, be approved.True copy.Jacques Prémont, Clerk of the Executive Council.QUÉBEC AGRICULTURAL MARKETING BOARD Take notice that on February 5, 1909, the Québec Agricultural Marketing Board adopted the following regulation: Regulations made pursuant to section U of the Dairy Products Act (RSQ 1964.chapter 121, amended by 16-18 Elizal>eth II, chapter 45) 1.A guarantee policy shall be issued by the Québec Agricultural Marketing Board to a milk dealer, holding a permit from the Board, and meeting the requirements hereunder mentioned.2.Each year, within 90 days following the end of his fiscal year, a milk dealer shall furnish the Board with a copy of the financial report of the said year including, among other things, a copy of his audited balance sheet, profit and loss accounts, redemption and capital.3.For the purpose of satisfying itself as to the dealer's solvency, the Board may require him to furnish any other information it may consider useful.4.Should the Board consider the milk dealer's solvency unsatisfactory, it may demand any other requirements it may deem necessary to ensure I he payment of the milk and cream delivered to the said milk dealer by the producer-suppliers.5.The milk dealer shall also, before the lir>l day of March of each year, inform the Board concerning the method of payment which he QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1833 producteurs-fournisseurs, ou un organisme chargé d'appliquer un plan conjoint dc producteurs-fournisseurs, pour la durée dc la police A lui être délivrée par la Régie.0.Ce mode de paiement doit s'effectuer conformément au règlement sur le paiement du lait et dc la crème aux producteurs-fournisseurs, adopté en vertu de l'article 21 de la Loi des produits laitiers.7.I«e montant d'assurance accordé au marchand dc lait par la police dc garantie que lui délivre la Régie représente le volume de ses trois plus fortes réceptions mensuelles de lait, dc lait modifié ou dc crème, provenant des producteurs-fournisseurs au cours de l'année précédente.La prime est calculée sur le volume total de ses réceptions durant l'année précédente, en prenant les prix du lait, du lait modifié ou dc la crème qui, de l'avis de la Régie, existent au moment du commencement de la police.Cependant, advenant une modification dans ses réceptions ou les prix pendant la durée de la police, le montant d'assurance pourra être modifié par la Régie.S.I.c taux dc la prime annuelle est de $1.25 par $1,000 de valeur de réceptions, jusqu'à concurrence de $3,000,000.par année; ce taux demeure sujet i\\ révision chaque année.!).Lu Régie adresse, au moins quinze jour» avant la délivrance de la police, un avis de prime au marchand dc lait, mentionnant le montant d'assurance qu'elle lui accorde et le montant de la prime qu'il doit payer en conséquence.Cet avis de prime, pour le montant d'assurance, peut être selon la formule ci-jointe.10.Le marchand de lait doit acquitter la prime dans les dix jours dc la réception de l'avis de prime.11.La police expire le 31 mars de chaque année; la Régie peut cependant en délivrer une nouvelle pour une autre année, avec ou sans changement, selon les circonstances.12.A l'expiration dc la police, la Régie procède A une vérification de la valeur des réceptions dc lait, île lait modifié ou dc crème par le marchand de lait, au cours dc l'année précédente, afin de déterminer s'il a droit à une ristourne ou doit payer un supplément de prime, la ristourne lui étant créditée sur la prime et le supplément étant ajouté à la prime d'une police subséquente.Le marchand «le lait recevra l'excédent ou paiera le supplément dc prime, selon le cas, s'il cesse de faire affaires pendant la durée ou à l'expiration de la police, pour une cause autre que la liquidation volontaire ou forcée.S'il y a liquidation, le débiteur devra payer le supplément de prime, mais ne pourra recevoir l'excédent dc prime.13.La Régie peut annuler, pour cause, une (Milice sur un avis de trois jours il cet effet au débiteur, mais sans remboursement de prime.La Régie doit informer les producteurs créanciers du débiteur aussitôt qu'elle annule la police dc ce dernier.14.La Régie, dès qu'elle constate le non-paiement A échéance par le marchand de lait des sommes «lues aux producteurs-fournisseurs ou à un organisme chargé d'appliquer un plan conjoint de producteurs-fournisseurs, pour du lait ou de la crème livré, met ce dernier en demeure, par lettre recommandée, d'acquitter cette dette dans les trois jours de la réception «le telle mise en has agreed on with his producer-suppliers, or with a body charged with the application of a joint plan of producer-suppliers, for the term of the policy issued to him by the Board.6.Such payment pattern must be made in conformity with the regulations concerning payment to producer-suppliers for milk and cream adopted under section 21 of the Dairy Products Act.7.The amount of insurance allowed to a milk dealer under the terms of the policy issued to him by the Board shall represent the volume of his three highest monthly receptions of milk, modified milk or cream from the producer-suppliers during the preceding year.The amount of the premium shall be based on the total volume of his receptions during the preceding year and on the prices for milk, modified milk and cream prevailing, in the opinion of the Board, at the time when the policy comes into force.However, in the event of a change in his receptions or in prices during the period covered by the policy, the amount of insurance may be adjusted by the Board.8.The rate of the yearly premium shall be SI .25 per $1,000 of the value of the milk dealer's receptions, up to a limit of $3,000,000 a year, with the proviso that this rate shall remain subject to annual revision.9.At least fifteen days before the policy is issued, the Board shall send the milk dealer a notice of premium stating the amount of insurance he is allowed and the amount of the premium he must pay in consequence.The said notice of premium for the amount of insurance in question must be given on a form like the one hereto appended.10.The milk dealer must pay the premium within ten days after receipt of the notice of premium.11.The policy shall expire on March 31st of each year but the Board may issue a new one for a further year, with or without changes as circumstances may require.12.Upon the expiration of the policy, the Board shall verify the value of the milk dealer's receptions of milk, modified milk or cream during the preceding year in order to decide whether he is entitled to a rebate or must pay an additional premium; in the former case, the premium on his subsequent policy shall be diminished by the amount of the rebate and in the latter cose it shall be increased by the amount of the additional premium.If the milk dealer goes out of business during the period covered by the policy or upon its expiration, for any reason other than voluntary or forced liquidation, he shall receive the surplus premium or pay the additional premium, as the case may be.Following a liquidation, the debtor must pay the additional premium but may not receive the surplus.13.The Board may, upon sufficient grounds, cancel a policy on three days notice to that effect to the debtor, and without reimbursing the pre-niiim.As soon as the Board cancels a debtor's policy, it must inform his creditors of the fact without delay.14.When the Board finds that sums owed by a milk dealer to producer-suppliers or to a body charged with the application of a joint plan of producer-suppliers arc not being paid when due, it shall send the milk dealer, by registered mail, a formal demand to pay the said sums within three days of receiving such notice; failing which, the policy shall be cancelled without further warning 1834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 10V année, n° 12 demeure: à défaut de quoi, la police est annulée sans autre avis, les producteurs créanciers du débiteur en étant avisés aussitôt par la Régie.15.La Régie doit acquitter, dans un délai dc trente jours suivant cet avis de trois jours, à la place du marchand dc lait, les sommes ducs par celui-ci à ses producteurs-fournisseurs ou il l'organisme chargé d'appliquer un plan conjoint île producteurs-fournisseurs, jusqu'à concurrence du montant garanti.16.Si la Régie ne possède pas un état complet et détaillé des sommes ducs par le marchand de lait à ses producteurs-fournisseurs ou à un organisme chargé d'appliquer un plan conjoint des producteurs-fournisseurs, ce délai de trente jours commence à courir à partir de la date où la Régie a obtenu de ces derniers tous les renseignements requis pom- acquitter leurs créances, la Régie devant les aviser sans délai, s'il y a lieu, après su mise en demeure de trois jours au marchand de lait, de produire leurs créances.17.La Régie est subrogée dans les droits des producteurs-fournisseurs ou dc l'organisme chargé d'appliquer un plan conjoint dc producteurs-fournisseurs contre le marchand dc lait, pour les créances qu'elle a ainsi acquittées, et peut recouvrer dans ce dernier les montants qu'elle a payés pour lui aux producteurs-fournisseurs ou a l'organisme chargé d'appliquer un plan conjoint dc producteurs-fournisseurs.18.Lorsqu'un tiers effectue le paiement du luit et tic la crème livrés par les producteurs-fournisseurs au nom du marchand dc lnit, la Régie est dégagée des obligations assumées en vertu des présentes, tant vis-à-vis les produetcurs-fournissers que du tiers.19.La police de garantie délivrée par la Régie doit être conforme, quant à ses conventions et conditions, à la formule de police ci-jointe.20.La Régie expédie au marchand dc lait la police de garantie en duplicata; ce dernier signe les deux exemplaires, en retourne un à la Régie et conserve l'autre.21.\\x présent règlement remplace celui adopté le 3 mai 1967 et entre en vigueur le 1er avril 1969.Montréal, ce cinquième jour de février 1969.Topic certifiée.REGIE DES MARCHÉS AGRICOLES DU QUÉBEC 201 est, boulevard Crémazic, Montréal 351.Avis de prime A: Nom.Adresse.Permis No., marchand dc lait.Dc: La Régie des marchés agricoles du Québec.Conformément aux règlements et à l'ordonnance de la Régie, votre prime de police d'assurance est de , pour un montant de garantie dc ; cette assurance vaut pour la période du au Cette prime doit être versée dans les dix jours de la réception du présent avis, par chèque visé ou par mandat fait à l'ordre tie la Régie des marchés agricoles du Quél>ec.Montréal, ce and the milk dealer's creditors shall be immediately notified of the fact by the Board.15.Within thirty days of the expiry of the aforesaid three-day notice, the Board, in lieu of the milk dealer, shall pay the sums which ho owes to his producer-suppliers or to the body charged with the application of a joint plan (if producer-suppliers, up to the limit of the guaranteed amount.16.If the Board does not have a complete and deluded statement of the sums owed by the milk dealer to his producer-suppliers or to a body charged with the application of a joint plan of producer-suppliers, the said respite of thirty days shall start from the date when the Board has obtained from them all the information needed to pay their claims, the Board being responsible, if necessary, for notifying them immediately upon expiry of the three-day formal notice to the milk dealer, to produce a statement of their claims.17.The Board is subrogated in the rights of the producer-suppliers or of the body charged with the application of a joint plan of producer-suppliers, as against the milk dealer, with respect to the debts which it has thus paid, and it may recover from the milk dealer the sums thai it has paid on his behalf to producer-suppliers or to such a l)ody.18.Whenever a third party effects the payment of milk or cream received by producer-suppliers in the name of the milk dealer, the Board is freed from obligations assumed pursuant to the presents towards the producer-suppliers as well as third parties.19.As regards its terms and conditions, the guarantee policy issued by the Board shall he in conformity with the policy form hereto ap|>cndcd.20.The Board shall send two copies of the guarantee policy to the milk dealer, who must sign both of them, keep one of them himself, and return the other to the Board.21.The present regulation replaces the one adopted on May 3, 1967 and it shall come into force on April 1, 1969.Montreal, this fifth day of February, 1909.Certified true copy.QUÉBEC AGRICULTURAL MARKETING BOARD, 201 Crémazie Boulevard East, Montreal 354.Notice of Premium To: Name.Address.Milk dealer's permit No.From : The Québec Agricultural Marketing Board.In accordance with the hcretp appended Regulations and order, your insurance policy premium is for a total guarantee of ; this insurance is valid for the period beginning and ending The premium must be paid within ten days of receipt of this notice, by cheque or money order payable to the Québec Agricultural Marketing Board.Montreal, this QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1909, Vol.101, No.12 1835 RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES DU QUÉBEC Cautionnement No Permis No Police ije ciahantie Loi des produits laitiers Marchand de lait Adresse: Moulant dc la garantie: Prime: Durée: 1° En considération dc lu prime ci-dessus'indi-(juée, lu Régie des marchés agricoles du Québec, ci-après appelée la caution, garantit, jusqu'à concurrence du montant plus haut mentionné, le paiement des sommes que doit ou pourra devoir pour du lait ou dc la crème livré le marchand dc lu il ci-dessus décrit, et ci-après appelé le débiteur, à ses producteurs-fournisseurs ou à un organisme les représentant en vertu d'un plan conjoint de producteurs-fournisseurs, ci-après appelés créanciers.2° Les comptes dûs à ses créanciers par le débiteur sont payables, pour la durée dc la police, selon l'échéance convenue entre eux et lui, dont avis est donné à la caution par ce dernier avant le 1er mars dc chaque année.3° Le paiement s'effectue en argent ou par chèque, remis directement aux créanciers par le débuteur, scion le mode prévu au règlement concernant le paiement du lait et de la crème au producteur-fournisseur, adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe H de l'article 21 dc la Loi des produits laitiers.¦1° bu caution, aussitôt, qu'elle constate le non-paiement ù échéance des comptes dûs à ses créanciers par le débiteur, met ce dernier en demeure, par lettres recommandée, d'acquitter tels comptes dans les trois jours: à défaut dc quoi, la |>olicc de garantie sera annulée sans autre avis, les créanciers du débiteur en étant avisés par la caution.5° Si, à l'expiration de ce délai dc trois jours, les comptes de ses créanciers n'ont pas été acquittés par le débiteur, la caution doit en effectuer, dans les trente jours suivants, le paiement à sa place.0° Si la caution ne possède pas un état complet cl détaillé des comptes dûs par le débiteur à ses créanciers, ce délai de trente jours commence à courir à partir de la date où la caution a obtenu de ces derniers tous les renseignements requis pour acquitter leurs comptes à la place du débiteur.7° La caution doit aviser sans délai les créanciers, après sa mise en demeure dc trois jours au débiteur, de produire leurs créances si besoin en est.S\" La caution qui a acquitté pour le débiteur les comptes de ses créanciers est subrogée dans les droits de ces derniers contre le débiteur, et elle peul en recouvrer le montant ainsi payé aux créanciers.9° Si un tiers effectue le paiement du lait et dc la crème livré par les créanciers au nom du débiteur, la caution est dégagée des obligations assumées en vertu de la présente police, tant vis-à-vis les créanciers que du tiers.10° Lu présente police expire le 31 mnrs suivant son émission.QUÉBEC AGRICULTURAL MARKETING BOARD Surety bond No.Permit No.Guarantee Policy Dairy Products AH Milk dealer: Address: Amount of guarantee: Premium: Duration: 1.In consideration of the abovemcntioncd premium, the Québec Agricultural Marketing Board, hereinafter referred to as the surety, guarantees payment of sums, not exceeding the abovemcntioncd total amount, which arc or may be owed for milk or cream delivered, by the abovenamcd milk dealer, hereinafter referred to as the debtor, to his producerrsupplicrs or to a body representing them through a joint plan of producer-suppliers, hereinafter referred to as the creditors.2.Accounts owing to his creditors by the debtor shall be payable, during the period covered by the policy, on the dates and terms which have been agreed on between them and him and which he shall make known to the surety before the 1st day of March of each year.3.Payment of the said accounts shall be made directly to the creditors by the debtpr, in cash or by cheque, in the manner stipulated in the regulations concerning payment to producer-suppliers for milk and cream passed by the Lieutenant-Governor in Council by virtue of paragraph H of article 21 of the Dairy Products Act.4.As soon as the surety finds that accounts payable by the debtor to his crcditbrs arc not being paid when due, it shall send the debtor, by registered mail, a formal demand to pay the said accounts within three days of receiving such demand, failing which, the guarantee policy shall be cancelled without further wurning and the debtor's creditors shall be immediately notified of the fact by the surety.5.If, on the expiry of the aforesaid three days' notice, the debtor has not paid the accounts of his creditors, the surety shall pay them in lieu of him within the thirty days following.0.If the surety does not have a complete and detailed statement of the accounts owed by the debtor to his creditors, the aforesaid respite of thirty days shall start from the date when the surety has obtained from the creditors all the information it needs to pay their accounts in lieu of the debtor.7.Immediately upon expiry of three-days' formal notice to the debtor, the surety shall, if necessary, notify the creditors to submit their claims.8.The surety is subrogated in the creditors' rights, as against the debtor, with respect to the debts which it has paid on his behalf and it may recover from him the sums it has thus paid to his creditors.9.Whenever a third party effects the payment of milk or cream received by producer-suppliers in the name of the milk dealer, the Board is freed from obligations, assumed pursuant to the presents, towards the producer-suppliers as well as towards the third party.10.This policy shall expire on the 31st day of March following its date of issue. 1830 CAZETTK OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mare 1969, 101' année, «\" 12 11° À l'exception «le In iwlicc, le débiteur a droit à un crédit dc prime ou «loit payer un supplément de prime selon «juc les états fournis par lui a la caution, et après vérification par cette dernière, révèlent que le montant d'assurance indiqué dans la police était trop ou pas assez élevé, compte tenu «lu volume et de la valeur dc ses réception au cours dc l'année précédente.12° La caution peut, pou r cause, mettre fin à la police, sur avis dc trois jours au débiteur à cet effet, mais sans remboursement «le la prime.13° La caution doit en informer les créanciers du débiteur aussitôt qu'elle annule la police de ce dernier ou lui en refuse le renouvellement.Date d'émission pour le débiteur Pour la Régie des marches agricoles du Quebec 28445-0 Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 078 Québec, le 12 murs 1969.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant In réserve de chasse et de pêche «le Forestvillc.Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6 «le l'article 65 de la Loi dc la chasse, Statuts refondus 1964, chapitre 202, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer «les réserves de chasse et «le pèche et y déterminer des règlements; Attendu Qu'il est apportun de modifier le paragraphe 5° des règlements dc ladite réserve.Il est oddonxé, en conséquence, sur la pro-po-itions du ministre du tourisme, de In chasse et «le la pêche : Que le paragraphe 5° «le l'arrêté en conseil numéro 3376 du 16 octobre 1968, concernant la réserve dc chasse et de pêche «le Forestvillc, soit révoqué et remplacé par le suivant: « 5° Aucune personne autre qu'un exploitant forestier ne peut ériger ou acheter des constructions dans la réserve, sans obtenir la permission du ministère et du ministère «les terres et forêts; » Que publication soit fuite dans la Gazelle officielle du Québec.Copie conforme.Le greffier du Conseil exécutif, 28449-0 Jacques Prémont.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 234 Québec, le 19 janvier 1969.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'application dc l'article 13 (j) et la Loi de l'impôt sur les corporation.Veuillez noter que la version anglaise du dernier paragraphe de cet arrêté en conseil aurait «lu se lire: This regulation shall apply to the financial year of every corporation commencing after the 31st of December 1967 » au lieu «le « Commencing on the 31st of December 1967».28477-0 11.Upon the expiration of the policy, the debtor shall be either entitled to a rebate on his premium or liable to pay an additional premium, according to whether the statement of accounts which he submits to the surety show-after verification by the latter, that the amount of insurance stated in the policy wns too high or to law in view of the quantity and value of his receptions during the preceding year.12.The surety may, upon sufficient grounds, cancel the policy on three days' notice to thai effect to the debtor, and without reimbursing the premium.13.As soon as the surety cancels or refuses to renew a debtor's policy, it must inform his creditors of the fact without delay.Date of issue For the debtor For the Québec Agricultural Marketing Hoard 28445 Order in Council Executive Council Chaml>cr Number 678 Québec, this March 12, 1909.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the Forestvillc Fish and Game Reserve.Whereas pursuant to paragraph 6 of section 65 of the Game Act, Revised Statutes.1904, chapter 202, the Lieutenant-Governor in Council may constitute fish and game reserves and determine the regulations to apply therein; Whereas it is expedient to amend paragraph .*> of the regulations of the said reserve.It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Tourism, Fish and Game: That paragraph 5 of Orxlcr in Council number 3376, dated October 16, 1968, concerning the Forestvillc Fish and Game Reserve, be revoked and replaced by the following: \"5.Nobody other than a forestry operator may erect or purchase buildings within the reserve unless he is granted a permit by the Department and the Department of Lands and Forests;\" That publication be made in the Québec Official Gazette.True copy.Jacques Prémont, 28449 Clerk of the Execulire Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 234 Québec, January 19, 1009.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the application of section 13 fj) and the Corporation Tax Act.Please note that the English version of the last paragraph of this Order in Council should have read: \"This regulation shall apply to the financial year of every corporation commencing aller the 31st of December 1967\" instead of \"Commencing on the 31st of December 1907\".28477 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, Mardi 22, 1969, Vol.101, No.12 1837 Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre Avis dc modification Coiffeurs \u2014 Roberral I.c ministre du Travail et dc la Main-d'oeuvrc, l'honorable Maurice Bellcmare, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective dc travail relative aux coiffeurs pour hommes et eoiireurs pour dames dans le comté de Roberval, rendue obligatoire par le décret numéro 1283 du lô novembre 1951 et modifications, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à.la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1° Remplacer l'article 102 par le suivant: ' 102 Jours fériés: Il n'y a pas de travail les dimanches, le premier jour de l'An, le 2 janvier, le mardi suivant la fête de Pâques, la Saint-Jean-Haptiste, la Confédération, le mardi qui suit la fêle du Travail, Noël et le 26 décembre.> 2° Remplacer l'article 106 par le suivant: i 100 Congé payé annuel: a) Tout employeur assujetti nu présent décret doit donner, chaque année, un congé payé annuel à ses salariés, de la façon suivante: 1.S'il n'a pas une (1) année dc service continu chez son employeur, tout salarié a droit ) L'indemnité afférente au congé est égale à quatre |>our cent (4%) du salaire brut gagné par le salarié au cours de la période de référence.c) Le salarié choisit la date dc sa première semaine de congé; quant ii In deuxième semaine, la date en sera fixée par entente entre l'employeur et le salarié.il) Les salariés coiffeurs pour dames auront droit à trois (3) jours de congés dc maladie payés, par année.Ces journées ne seront pas cumulatives.» 3° Remplacer l'article 108 par le suivant: \u2022 108 Le salaire minimal payable aux salariés est le suivant : u) Employé permanent: l'oiffeur pour hommes, classe « .1 »: 800 par semaine, plus 50% des recettes dc son travail qui excèdent 876 par semaine.Coiffeurs pour hommes, classe « B »: $56 par .semaine, plus 50% des recettes dc son travail qui excèdent $72 par semaine.'d Employé surnuméraire ou remplaçant: 70% des recettes brutes enregistrées.c) Apprenti: Première année: 822 par semaine, plus 50% «les recettes dépassant 832 par semaine.Department of Labour and Manpower Notice of Amendment Hairdressers \u2014 Roberral Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, chapter 143), the Honourable Maurice Bellcmare, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that the contracting parties to the collective labour agreement respecting men's and ladies' hairdressers in Roberval County, made binding by decree number 1283 of November 15, 1951 as amended, have petitioned him to submit the following amendments to the said decree to the Lieutenant Governor in Council for consideration and decision : 1.Section 102 will be replaced by the following: \"102.General Holidays: No work shall be performed on: Sundays, New Year's Day, January 2nd, the first Tuesday after Easter, St.John the Baptiste Day, Canada Day, the first Tuesday after Labour Day, Christmas Dav and December 26th.\" 2.Section 106 will be replaced by the following: \"106.Annual vacation with pay: (a) Any employer subject to the present decree shall yearly grant his employees annual vacations with pay as follows: 1.Any employee who has less than one (I) year's continuous service with his employer is entitled to a continuous annual vacation with pay the duration of which shall be of one (1) day's vacation for every month's service.However, the duration of such vacation shall not exceed two (2) weeks.2.Any employee who has one or more years' continuous service with his employer is entitled to two (2) weeks' continuous annual vacation with pay.(6) Vacation pay is equal to four per cent (4%) of the employee's gross earnings for the qualifying period.(c) The employee shall set the date for his first week's vacation; the date on which the second week's vacation is to be taken shall be determined following an agreement between the employer and the employee concerned.(«f) Ladies' hairdressers shall be entitled to three (3) days' sick leave with pay each year.These days' sick leave shall not be cumulative.\" 3.Section 108 will be replaced by the following: \"108.Minimum wages paid to employees arc as follows: (a) Regular employee: Men's hairdresser.Class \"A\": 800 a week, plus 50% of the receipts of his work exceeding S7(i during the week.Men's hairdresser, Class \"B\": 856 a week, plus 50% of the receipts of his work exceeding S72 during the week.(b) Temporary or substitute employee: 70% of gross receipts recorded.(c) Apprentice: First year: $22 a week, plus 50% of weekly receipts cxweiling 832. 1838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, «° 12 Deuxième année: $30 par semaine, plus 50% des recettes dépassant $40 par semaine.Troisième année: $38 par semaine, plus 50% des recettes dépassant $48 par semaine.» 4° Remplacer l'article 109 par le suivant: « 109 Durée du travail: Dans les salons de coiffeurs pour hommes, les heures normales de travail sont réparties dc la façon suivante: Le lundi: chômé; les mardi, mercredi, jeudi et samedi: dc 8 h du matin à 5 h.30 de l'après-midi; Le vendredi ainsi que les trois (3) jours ouvrables précédant immédiatement la veille de Noël : dc 8 h du matin à 9 h du soir.Toutefois, les heures de travail sont dc 8 h du matin à 5 h.30 dc l'après-midi, le lundi précédant la fête dc Noel, lorsque celle-ci tombe un jour ouvrable.» 5° Remplacer l'article 112 par le suivant: « 112 Le salaire minimal payable aux salariés est le suivant: a) Employé permanent: Coiffeur pour dames, classe « A »: $50 par semaine, plus 30% des recettes de son travail excédant $100 au cours de la semaine.Coiffeurs pour dames, classe « B »: $45 par semaine, plus 25% des recettes de son travail excédant $100 au cours dc la semaine.Par b) Apprenti: semaine Les 6 premiers mois.$30 De 6 à 12 mois.32 Deuxième année.36 Troisième année.42» 6° Remplacer l'article 113 par le suivant: « 113 Durée du Travail: Dans les salons dc coiffeurs pour dames, les heures normales dc travail sont réparties de la façon suivante: Le lundi: de 1 h à 5 h.30 de l'après-midi; Les mardi, mercredi et jeudi: dc 8 h.30 du matin à 5h.30 de l'après-midi; Le vendredi: dc 8 h du matin à 9 h du soir; Le samedi: dc 7 h du matin i\\ midi; La veille de Noël, du premier jour dc l'An et de Pâques: de 7 h du matin à 5 h.30 de l'après-midi; Les trois (3) jours ouvrables prédédant immédiatement la veille de Noël et du premier jour de l'An : de 8 h du matin à 9 h du soir.Cependant, le samedi, une heure et demie (\\]/>) est allouée pour terminer le travail rendu nécessaire par la présence des clientes entrées avant midi.Toutefois, les heures dc travail sont dc 8 h.30 du matin à 5 h.30 dc l'après-midi, le lundi, lorsque le mardi est un jour férié mentionné à l'article 102, ainsi que le lundi prédédant Noël et le premier jour de l'An, lorsque ces fêtes tombent un jour ouvrable.» 7° À l'article 114, majorer le prix minimal de l'ondulation ù l'eau de $1.50 à $1.75 et ajouter la clause suivante: « Note: Les prix minimaux ci-haut déterminés s'appliquent également lorsque le travail est exécuté sur une perruque ou un postiche.» 8° Les parties contractantes ont également sollicité une majoration des prix minimaux des services suivants: Second year: $30 a week, plus 50% of weekly receipts exceeding $40.Third year: $38 a week, plus 50% of weekly receipts exceeding $48.\" 4.Section 109 will be replaced by the following: \"109.Hours of work: In men's hairdressing salons, standard working hours are scheduled as follows: Monday: non-working day; Tuesday, Wednesday, Thursday and Saturday: 8:00 a.m.to 5:30 p.m.; Friday and the three (3) working days immediately preceding Christmas Eve: 8:00 a.m.lo 9:00 p.m.However, hours of work arc from 8:0(1 a m.to 5:30 p.m.on the Monday before Christmas Day, when Christmas falls on a working day.\" 5.Section 112 will be replaced by the following: \"112.Minimum wages payable to employees arc as follows: («) Regular employee: Ladies' hairdresser.Class \"A\": $50 a week, plus 30% of his (her) work's wccklv receipts exceeding $100.Ladies' hairdresser, Class \"B\": $45 a week, plus 25% of his (her) work's weekly receipts exceeding $100.Per (t») Apprentice: week First six months.$30 Second six months.32 Second year.36 Third year.42\" 6.Section 113 will be replaced by the following: \"113.Hours of work: In ladies' hairdressing salons, standard working hours are scheduled as follows: Monday: 1:00 p.m.to 5:30 p.m.; Tuesday, Wednesday and Thursday: 8:3(1 a.m.to 5:30 p.m.; Friday: 8:00 a.m.to 9:00 p.m.; Saturday: 7:00 a.m.to 12:00 o'clock noon; On the eve of Christmas, of New Year's Day and of Easter: 7:00 a.m.to 5:30 p.m.; On the three (3) working days immediately preceding Christmas Eve and New Year's Eve: 8:00 a.m.to 9:00 p.m.However, one hour and a half (\\l/-> hour' are allowed on Saturday to finish work on customers who were in the salon before noon.However, hours of work on Monday are from 8:30 a.m.to 5:30 p.m.when Tuesday is a general holiday mentioned in section 102 as well as on the Monday preceding Christmas Day and New Year's Day when the latter general holidays fall on a working day.\" 7.In section 114, the minimum price for \\\\ «1er Wave will be increased from $1.50 to 81.75, and the following clause will be added: \"Note: The above-mentioned minimum prices ulso apply when the work involved is performed on a wig or hairpiece.\" 8.The contracting parties are also seeking an increase in the minimum price of the following services: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1909, Vol.101, No.12 1839 « Coiffeurs four hommes \u2014 Men's hairdressers (article 110) \u2014 (section 110) Prix actuel Prix demandé Actual price Price sought ( loupe de cheveux ordinaire pour adultes \u2014 Regular haircut, adults.$1.25 SI .75 Coupe de cheveux ordinaire pour enfants de moins de 14 ans \u2014 Regular haircut, children under 14.0.80 1.25 ( loupe de cheveux en brosse pour udultcs \u2014 Brushcut adults.1.50 2.00 ( loupe de cheveux en brosse pour enfants de moins de 14 ans \u2014 Brushcut, children under 14.1.00 1.50 ( loupe de cheveux au rasoir, y compris shampooing et ondulation \u2014 Razor cut, including shampoo and setting.3.25 4.00 Barbe \u2014 Shave.-.0.90 1.25 Flambage des cheveux \u2014 Singeing hair.0.35 0.50 Shampooing \u2014 Shampoo.1.00 1.00 .\\ I assage \u2014 Massage.1.00 1.25 Lotion, tonique ou fixatif \u2014 Lotion, tonic or hair-sctting solution.0.35 0.50 Aiguisage dc rasoir \u2014 Razor honing.0.75 1.00 Teinture \u2014 Dyeing.\u2014 4.00 Mise en plis \u2014 Setting.\u2014 1.00 Note: Les prix minimaux ci-haut déterminés Note: The minimum prices determined above s'appliquent également lorsque le travail est also apply when the work involved is performed exécuté sur une perruque ou un postiche.» on a wig or hairpiece.\" La publication du présent avis ne rend pas Publication of this notice docs not make bind- obligatoires les dispositions qui y sont contenues, ing the provisions therein.Such provisions, with Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires or without amendments, can be made binding ces dispositions, avec ou sans amendements, only by an order in council that cannot come into L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur force before the date of its publication in the avant la date dc sa publication dans la Gazette Québec Officiai Gazette, officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date During the thirty days following publication dc publication'.'dé cet avis dans la Gazetle officielle of this notice in the Quebec Official Gazette, the du Québec, l'honorable ministre du Travail et dc Honourable Minister of Labour and Manpower la Main-d'œuvre recevra les objections que les will consider objections which interested parties intéresses pourront désirer formuler.may wish to make.Le sous-ministre du Travail Don at Quimpek, el de la Main-d'œuvre.Deputy Minister of Labour Donat Qoimpek.and Manpower.Ministère du Travail et de la Main-d'œuvre, Department of Labour and Manpower, Québec, le 22 mars 1969.2S401-o Québec, March 22, 1909.28401-0 Avis dc modification Notice of Amciidnu-ni Coiffeurs\u2014 Chicoutimi Hairdressing Trades \u2014 Chicoutimi Region Le ministre du Travail et dc la Main-d'œuvre, Pursuant to the provisions of the Collective l'honorable Maurice Bellcmare, donne avis par Agreement Decrees Act (RSQ 1904, c.143), the les présentes, conformément aux dispositions de Honourable Maurice Bellcmare, Minister of la Loi des décrets dc convention collective Labour and Manpower, hereby gives notice that 'Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 143), the contracting parties to the collective labour que les parties contractantes à la convention agreement respecting the Hairdressing Trades in collective dc travail relative aux coiffeurs pour the electoral districts of Chicoutimi, Dubue, hommes et coiffeurs pour dames dans les districts Jonquièrc-Kénogami and Lac St-Jcnn (made électoraux de Chicoutimi, Dubuc, Jonquière- binding by Decree number 977 of June 14, 1960, Kcnogami et Lhc Saint-Jean, rendue obligatoire as amended) have petitioned him to submit the par le décret numéro 977 du 14 juin i960 et following amendments to the said decree to the amendements, lui ont présenté une requête à Lieutenant-Governor in Council, for considera- l'cffct de soumettre à l'appréciation et à la t ion and decision: décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1° Remplacer le paragraphe « a » de l'article 1.Subsection \"a\" of section 102 will be super- 102 par le suivant: seded by the following: « 102.a) Coiffeurs pour hommes: Tout travail \"102.(a) Men's hairdressers: No work may be est interdit les dimanches et les jours de fêtes performed on Sundays and on the following suivants: le premier jour de l'An, le 2 janvier, general holidays: New Year's Day, January 2nd, le lundi de Pâques, la Saint-Jean-Baptiste, la Éaster Monday, St.John the Baptist Day, Confédération, la fête du Travail, Noël et le 26 Canada Day, Labour Day, Christmas Day and décembre » December 20tlv.\" 2° Remplacer le deuxième alinéa du para- 2.The second paragraph of subsection \"b\", graphe « b » de l'article 102 par le suivant: section 102, will be replaced by the following: * Toutefois, dans la zone I, les fêtes de I'Ascen- \"However, in zone I, Ascension Day, All Saints' sion, de la Toussaint et do l'Immaculée-Concep- Day and Immaculate Conception Day are lion soul des jours ouvrables aux heures norma- working days with standard working hours.\" les.¦» 1840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 mars 19G9, 101' année, n° 12 3° Remplacer l'horaire de travail des coiffeurs 3.In section 112, the work schedule for men's pour hommes de la zone I, apparaissant à l'ar- hairdressers will be superseded by the following: tide 112, par le suivant: « Coiffeurs pour hommes \"Men's hairdressers Zone I Zone I Quarante-quatre (44) heures par semaine Forty-four (44) hours a week scheduled us réparties comme suit: follows: Le lundi: chômé, excepté dans les cas ci-après Monday: non-working day, save for exceptions mentionnes.listed below; Les mardi, mercredi, jeudi et samedi: de 8 Tuesday, Wednesday, Thursday and Sat unlay: heures a.m.à 5.30 heures p.m.8:00 a.m.to 5:30 p.m.; Le vendredi, la veille des fêtes chômées et les Friday, the eves of general holidays and the trois (3) jours ouvrables précédant immédiate- three (3) working days immediately preceding ment la veille de Noël: dc 8 heures a.m.n 9 heures Christmas Eve: 8:00 a.m.to 9:00 p.m.p.m.Exceptions: Exceptions: 1.La veille de Noël et du Premier jour de l'An, 1.On Christmas Eve ami New Year's Eve, les heures dc travail sont de 8 heures a.m.à working hours arc from 8:00 a.m.to 5:30 p.iu! 5.30 heures p.m.2.Nonobstant les dispositions des paragraphes 2.Notwithstanding the provisions of the précédents, lorsqu'un jour dc fête chômé tombe foregoing paragraphs, when a general holiday un mardi ou un samedi, le lundi qui précède ou falls on a Tuesday or a Saturday, working hours suit immédiatement cette fête, selon le cas, la shall he scheduled1 from 8:00 a.m.to 5:30 p.m.on durée du travail doit être de 8 heures a.m.à the Monday that either immediately precedes or 5.30 heures p.m.follows such general holiday.Cependant, si ce lundi tombe dans la période However, should such Monday fall on the des trois jours ouvrables avant la veille de Noël, three (3) working days immediately preceding les dispositions ei-dessus s'appliquent.Christmas Eve, the above provisions shall apply.3.La durée du travail s'étend de huit (8) 3.During July and August, hours of work on heures du matin à midi le samedi, durant les Saturdays shall be scheduled from 8:00 a.m.to mois de juillet et août.noon.4.A Alma, la durée du travail s'étend dc 8 4.In Alma, during June, July and August, heures a.m.à midi, le samedi, durant les mois dc working hours on Saturday shall be scheduled juin, juillet et août.» from 8:00 a.m.to noon.\" 4° À l'article 112, biffer l'exception 1 apparais- 4.In section 112, exception 1 to working hours saut à l'horaire de travail tic la zone IL for zone II .will be deleted.5° Les parties contractantes ont également 5.The contracting parties are also seeking an sollicité une majoration des prix minimaux pour increase in the minimum price of the following les services suivants: services: A \u2014 Coiffeurs pour hommes \u2014 Men's hairdressers (article 114) \u2014 (section 114) Prix actuel Prix demandé Actual price Price sought Zones Zones I II let-ami 11 Coupe de cheveux ordinaire pour adultes \u2014 Regular haircut, adults.SI .25 SI .25 81.75 Coupe de cheveux ordinaire pour enfants de moins dc 14 ans \u2014 Regular haircut, children under 14.0.75 0.70 1.00 Coupe de cheveux en brosse pour adultes\u2014Brushcut, adults.1.65 1.50 2.00 Coupe de cheveux en brosse pour enfants dc moins de 14 ans \u2014 Brushcut children under 14.1.00 0.90 1.25 < loupe «le cheveux au rasoir y compris shami>ooing et ondulation \u2014 Razor cut, including shampoo and setting.3.50 3.25 3.75 Noie: Les prix minimaux ci-haut déterminés Note: The above minimum prices also apply to s'appliquent également lorsque le travail est work done on a wig or a hairpiece, exécuté sur une perruque ou un postiche.B \u2014 Coiffeurs pour dames \u2014 Ladite' hairdressers (article 120) \u2014 (section 120) ( loupe dc cheveux pour adultes \u2014 Haircut, adults.SI .50 81 35 SI .75 SI 60 Coupe de cheveux pour enfants de moins de 14 ans \u2014 Haircut, children under 14.1.25 1.00 1.50 1 25 Ondulation à l'eau (mise en plis) \u2014 Setting.1.75 1.50 2.00 1 75 Décoloration, teinture et mise en plis au cours de la même visite \u2014 Colour-stripping, dyeing and setting at the same sitting.10.00 10.00 12.00 12,00 Rinçage nuanccur on colorant \u2014 Colour rinse or toner.2.00 2.01) 3.50 3.50 ^ Notes: Les prix minimaux ci-haut déterminés Noie: The above minimum prices also apply to s'appliquent également lorsque le travail est work done on a wig or a hairpiece, exécuté sur une perruque ou un postiche. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1909, Vol.101, No.12 1841 La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendements.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date dc sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication dc cet avis dans la Gazelle officielle du Québec, l'honorable ministre du Travail et dc la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre du Travail el de la Main-d'oeuvre, donat QuiMPER.Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, Québec, le 22 mars 1969.28401-o Avis dc modification Literie el rembourrage \u2014 Province de Québec Le ministre du Travail et dc la Main-d'ocuvre, l'honorable Maurice Bellcmare, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions dc la Loi des décrets de convention collective (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 143), (pic les parties contractantes à la convention collective dc travail relative à la fabrication de literie et au rembourrage dc meubles dans la province dc Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 2272 du 17 novembre 1965 et modifications, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil la modification suivante audit décret: Remplacer le paragraphe « a » de l'article IX (Congés annuels payés) par le suivant: < a) Durée du congé et indemnité de congés: Tout salarié assujetti au Décret, a droit à des congés payés annuels conformément aux dispositions suivantes: Ancienneté Seniority 1.Moins d'un an de service continu pour le même employeur pendant l'année de référence, à un congé payé continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour par mois de travail sans (pic la durée totale du congé exigible excède deux semaines.\u2014 Less than one year's continuous service with the same employer during the qualifying period: one day's continuous vacation with pay for each month worked, up to a maximum of two (2) weeks' vacation.2.Plus d'une année mais moins dc quinze (15) années de service continu pour le même employeur.\u2014 More than one (I) but less than fifteen (15) years' continuous service with the same employer: 3.Plus de quinze (15) années dc service continu pour le même employeur.More than fifteen (15) years' continuous service with the same employer: La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obliga- Publication of this notice does not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can be made binding only by an order in council that cannot come into force before the date of its publication in the Québec Official Gazelle.During the thirty days following publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour and Manpower will consider objections which interested parties may wish to make.Don at Quimi'eii, Deputy Minister of Labour and Manpower.Department of Labour and Manpower, Québec, March 22, 1969.28401-o Notice of Amendment Bedding and Upholstering Industry\u2014 Québec Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.143), the Honourable Maurice Bellcmare, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that the contracting parties to the collective labour agreement respecting the Bedding and Upholstering Industry in Québec (made binding by Decree number 2272 of November 17, 1965, as amended) have petitioned him to submit the following amendment to the said decree to the Lieutenant-Governor in Council, for consideration and decision: Subsection \"a\" of section IX (Annual vacation with pay) is superseded by the following: \"(a) Length of vacation and vacation pay: Every employee subject to this decree is entitled to annual vacations with pay, according to the following purposes: Publication of this notice does not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can be made Durée du conge Indemnité dc congé - %du total des gains Length of vacation Vacation pay - % of total earnings .4%.Toutefois, ladite indemnité est maintenue à 2% du salaire gagné pour la période antérieure au 1er janvier 1969.\u2014 However, vacation pay is maintained at 2% of wages earned for the period prior to January 1, 1969.2 semaines 2 weeks 3 semaines 3 weeks .4% Toutefois, pour les salariés qui ont moins de cinq (5) années de service ladite indemnité est maintenue à 2% du salaire gagné pour la période antérieure du 1er janvier 1969.\u2014 However, for employees with less than five (5) years' service, vacation pay is maintained at 2% of wages earned for the period prior to January 1st, 1969. 1842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 mars 1969, 101' année.n° 12 'mires ces dispositions, avec ou sans amendements.L'urrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de su publication duns lu Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours ù compter dc la date de publication de cet avis dans la Gazelle officielle du Québec, l'honorable ministre du Travail et dc la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, DONAT QUIMPER.Ministère du Travail et dc la Main-d'ocuvrc, Québec, le 22 mars 1969.28401-o Avis dc prélèvement L'honorable Maurice Bellcmare, ministre du Travail et dc la Main-d'oeuvre, donne avis par les présentes que le Comité paritaire des Directeurs de Funérailles, Be de Montréal et Ile Jésus, établi en exécution du décret numéro 932 du 6 mai 1964, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 599, du 5 mars 1969, le tout d'accord avec les dispositions de la Loi des décrets de conventions collective (S.R.Q.1964, c.143), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant les conditions ci-après décrites 1.Cotisai ion La période de cotisation s'étend du 13 mars 1969 au 13 mars 1970; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 932 et amendements, doivent verser an Comité paritaire une somme équivalente à \\ '> dc 1% dc leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 932 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à \\-> de 1% du salaire moyen établi à 8100 par semaine.c) Les salaries régis par ledit décret numéro 932 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à \\^ de 1% de leur rémunération.2.Mode dc perception En vue dc faciliter la perception dc ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la lin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé a ses salariés, au moyen d'une retenu sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le quinze (15) du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation dc l'employeur professionnel et de celles de ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'asser-inentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge h propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.binding only by an order in council that cannot come into force before the date of its publication in the Quebec Official Gazelle.During the thirty days following publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour and Manpower will consider objections which interested parties may wish to make.DONAT QuiMl'Eli, Deputy Minister of Labour and Manpower.Department of Labour and Manpower, Québec, March 22, 1969.28401-0 Notice of Levy Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q.1964, c.143).the Honourable Maurice Bellcmare, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that the Parity Committee of Funeral Directors of the Island of Montreal and Ile Jésus (established in pursuance of Decree number 932 of May 6, 1964 as amended) has been authorized to levy dues on the professional employers, artisans and employees subject to the said decree, according to the following conditions.A by-law, approved by Order in Council number 599, dated March 5, 1969, authorizes such levy.1.Dues The contribution period extends from March 13.1969 to March 13, 1970.The levy is carried out as follows: (a) Professional employers governed by said Decree number 932, as amended, shall pay the Parity Committee an amount equivalent to 1 .j of 1% of their payroll for employees subject to I he said decree.(6) Artisans governed by said Decree number 932, as amended, shall turn over to the Parity Committee an amount equivalent to \\A of 1% of the average weekly income fixed at 8100 per week.(c) Employees governed by said Decree number 932, as amended, shall turn over to the Parity Committee an amount equivalent to ]/> of 1',' of their wages.2.Collection of Dues To facilitate the collection of such ducs.I la-Parity Committee supplies professional employers with rei>ort forms on which must be noted all the information requested by the said Parity Committee.The professional employer shall complete, sign and forward his report monthly to the Parity Committee.At the end of each week and on behalf of I lie Committee, the professional employer shall collect the levy by means of a check-off.The professional employer must submit his monthly report to the Parity Committee on or before the 15th of the month following the expiry date of the period for which it is required.The professional employer's dues, together with those of his employees, shall accompany the said report.The Committee has the authority to request an attestation of the said reixu-t whenever it shall deem it advisable.The levy imposed by this by-law is payable monthly by the professional employer, the artisan and the employee, without formal notice beforehand. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1843 Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ses cotisations ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi des décrets de convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au ministre du Travail et de la Main-d'Oeuvre, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre dc chaque année.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés probables du Comité paritaire des Directeurs dc Funérailles, Ile de Montréal et Ile Jésus, pour la période comprise entre le 13 mars 1969 et le 13 mars 1970.Comité pahitaihe des directeurs de Funérailles, Ile de Montréal et Ile Jésus Ktal des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 13 mars 1969 et le 13 mars 1970.Recettes: ('otisalions patronales.S 5,000 ('otisations ouvrières.5,000 ('otisations nrtisanales.600 Dommages: Intérêts liquidés.200 Intérêts de banque.650 811,450 Déboursés: - Salaire du secrétaire.S 3,500 Salaires du personnel.1,040 Salaire de l'inspecteur.1,440 Frais d'inspection.720 Loyer et taxes.780 Frais judiciaires.200 Frais de vérification.200 Impression, papeterie, ace dc bureau .200 Poste, téléphone, télégramme.450 Intérêt, échange, agios.5 Jetons dc présence (membres du Comité) 420 Frais «le déplacements (membres du Comité).1,550 Frais dc délégation.000 Frais d'affiliation.50 Assurance-caution.20 811,175 Excédent des recettes sur les déboursés prévu.$ 275 Le sous-ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, Donat Quimper.Ministère du Travail et dc la Main-d'oeuvre, Québec, le 22 mars 1969.28401-o Should a professional employer or an artisan refuse to pay his dues or supply necessary information, he will be given five (5) days' notice so that he may fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial Report In compliance with the provisions of the Collective Agreement Decrees Act, the Parity Committee shall submit a quarterly financial report to the Minister of Labour on the following set dates: March 31st, June 30th, September 30th and December 31st of each year.An estimate of receipts and disbursements for the Parity Committee of Funeral Directors of the Island of Montreal and He Jésus for the March 13,1969 to March 13,1970 period is given below.Parity Committee of Funeral Directors of the Island of Montreal and Ile Jésus Estimate of receipts and disbursements for the March 13, 1969 to March 13, 1970 period.Receipts: Employers' dues.8 5,000 Employees' dues.5,000 Artisans' dues.600 Damages: paid-up interest.200 Bank interest.050 811,540 Disbursements: - Secretary's salary.S 3,500 Staff's salary.1,040 Inspectors' salaries.1,440 Inspection expenses., 720 Rent and taxes.* 780 Legal costs.200 Auditor's fees.200 Printing, stationery, office equipment.200 Postage, telephone, telegrams.450 Interest, exchange, agio.5 Attendance fees (Committee members).420 Travelling expenses (Committee members).1,550 Delegation expenses.600 Affiliation fees.50 Fidelity bond.20 811,175 Forecast surplus.S 275 Donat Quimper, Deputy Minister of Ixibour and Manpoiccr.Department of Labour and Manpower, Québec, March 22, 1909.28401-o Régie des Marchés Quebec Agricultural Agricoles du Québec Marketing Board Ordonnance No.G-5-1 Order No.G-5-1 (Échelle de la garantie) (Scale for guarantee) Considérant qu'il y a lieu d'établir une échelle Considering that it is expedient to establish a de la garantie qui doit être donnée par les mar- scale for the guarantee to be given by milk ehands de lait en faveur de leurs producteurs- dealers to their producer-suppliers; fournisseurs; 1844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 100' année, n' 12 Vu le paragraphe 2 de l'article 13, ainsi que les articles 8 à 12, dc la Loi des produits laitiers; Vu les règlements adoptés par la Régie des marchés agricoles «lu Québec le 5 février 1969; La Régie des marches agricoles du Québec ordonne ce qui suit: 1° Dans la présente ordonnance, les expressions « marchand dc luit», « producteur-fournisseur», « lait, lait modifié en crème » et « police » ont les mêmes significations qu'à la Loi des produits laitiers, et le mot « Régie » signifie la Régie des marchés agricoles du Québec.2° Le moulant de la garantie que doit fournir le marchand dc lait est établi d'après le volume des trois plus fortes réceptions mensuelles de lait, de lait modifié ou de crème provenant des producteurs-fournisseurs au cours dc l'année précédente.3° La prime de la police est calculée sur le volume total des réceptions dc lait, dc lait modifié ou «le crème par le marchand «le lait, au cours de l'année précédente, en prenant les prix de ces produits qui, «le l'avis dc la Régie, existent au moment du commencement «le la police et ce, jusqu'à concurrence «le réception d'une valeur dc 83,000,000.4° Si, au cours «le l'année précédente, le marchand de lait n'a pns acheté ou reçu «lu lait, du lait modifié ou «le la crème «le producteurs-fournisseurs, le montant de garantie est fixé à 850,000.et la prime est calculée sur ce montant, conformément nu taux fixé par le règlement prévu à l'article 9 «le la Loi des produits laitiers Le montant «le garantie pourra alors être revisé par la Régie en proportion du volume reçu ou acheté par le marchand «le lait après 3 mois d'exploitation.Cet article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un établissement laitier déjà en exploitation.5° Si le chèque représentant la somme duc a été remis au producteur-fournisseur dans le délai prévu au règlement concernant le paiement du lait et dc la crème adopté en vertu «le l'article 21 de la Loi des produits laitiers, la somme représentée par ce chèque ne sera plus considérée comme étant garantie par la police, si le producteur-fournisseur ne présente pas son chèque pour encaissement dans les 3 mois suivant son émission.6° La Régie peut en tout temps, même pciidnn 1 la durée d'une police, modifier le montant «le la garantie et de la prime exigée du marchand de lait si le volume dc ses réceptions «le lait, lait modifié ou de crème change, ou si, «lans l'opinion «le la Régie, les prix de ces produits sont modifiés.7° La présente ordonnance abroge l'ordonnance G-5, et entrera en vigueur le 1er avril 1969.Montréal, ce 5 février 1969.Copie certifiée conforme.Par le secrétaire intérimaire, 28445-0 Rocu Mown.In view of paragraph 2 of section 13, as well as sections 8 to 12 of the Dairy Products Act; Considering the regulations enacted by the Quebec Agricultural Marketing Board on February 5, 1969; The Québec Agricultural Marketing Board orders the following: 1.In this order, the expressions \"milkdcaler\", \"producer-supplier\", \"milk, modified milk or cream\" and \"policy\" have same meanings as in the Dairy Products Act, and the word \"Board\" means the Québec Agricultural Marketing Board.2.The amount of the guarantee which the dealer must supply is established according to the volume for the three largest monthly milk receptions modified milk or cream which he lias received from producer-suppliers during (lie course of the preceding year.3.The premium of the policy is based upon the total volume of milk, modified milk or cream received by the milk dealer, during the course of the preceding year, taking into considérai ion the prices of Ihcsc products which, in the Opinion of the Board, exist at the moment when (he policy comes into effect, and such, to the receipt of a value of 83,000,000.4.If, during the course of the preceding year, the milk dealer has not bought or received milk, modified milk or cream from producer-suppliers, the amount of the guarantee is fixed at 850.111)0.and the premium is based on this amount, pursuant to the rates fixed by the by-law contemplated in section 9 of the Dairy Products Act.The amount of the guarantee may then be revised by the Board in proportion to the volume received or bought by the milk dealer after 3 months of opcrutinn.This section does not apply in the case of a dairy establishment already in operation.5.If the cheque representing the amount due has been sent to the producer-supplier within the «lclay provided for in the by-law concerning the payment for milk and cream, adopted in virtue of section 21 of the Dairy Products Act, the sum represented by this cheque will no longer be considered as being guarantceil by the policy, if the producer-supplier docs not present his cheque for paying in within the 3 months follow -ing its issue.6.At any time, even during the term of n policy, the Board may amend the amount of the guarantee and of the premium required of the milk dealer if the volume of the milk, modified milk or cream which he receives changes, or if.in the opinion of the Board, the prices of these product s arc modified.7.The present order repeals order G-5, and shall come into force on April 1st.1969.Montreal, February 5, 1969.Certified true copy.By: Roch Moiiin.28445-o Acting Secretary.Ministère des Terres et Forêts Department of Lands and Foresl s Paroisse de Stc-Foyc Parish of Ste-Foye Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Foye, Official cadastre of the parish of Ste-Foye, municipalité de la ville «le Ste-Foy, division municipality of the town of Ste-Foy.rcgistra- d'enregistrement «le Québec.tion division of Québec. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1845 Avis est par la présente donné que les lots 414-209-1 et 414-209-2 sont annulés en vertu cc to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable André Taschereau, ll.d., d.c.l., Judge of the Court of Queen's Bench, Government administrator of the Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our city of Québec, in Our Province of Québec, this eleventh day of March, in the year of Our Ixml one thousand nine hundred and sixty-nine and in the eighteenth year of Our Reign.By command, Raymond Douville, 28400 Assistant Secretary of the Province.Le sous-secrétaire de la province, 2S400-o Raymond Douville. 1848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 mars 19G9, 101' année, n' 12 Changement de nom \u2014 Loi du Harry Kamcnetsky Avis est par les présentes donné que Harry Kamcnetsky, étudiant, domicilié à 327, boulevard Alexis-Ninon, Ville Saint-Laurent, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui dc Harry Kamen; ledit cliange-ment dc nom s'appliquera aussi ù son épouse, nee Miriam (Myra) Bloom, et son fils mineur, Allan Gerald, tous dc la même adresse.Montreal, le 3 mars 1969.Les procureurs du requérant, 28311-11-2 Frankei.& Frankel.D'Arcy Puni Olcskcvis Avis est donne qu'en vertu de la Loi du changement de nom, 13-14, Eliz.H, chap.77, une requête sera faite demandant le changement de nom suivant: D'Arcy Paul Olcskcvis, assistant ingénieur, domicilié et résidant à 3415, avenue Girouard, app.512, en la ville' de Montréal, district de Montréal, s'adressera au secrétaire dc la province afin que sou nom soit change en celui de D'Arcy Paul Paul.Le notaire du requérant, 28312-11-2 Davii» Adrams.Paul Andrew Oleskevis Avis est donné qu'en vertu de la Loi du changement dc nom 13-14, KHz.II, cliapitrc 77, une requête sera fuite demandant le changement dc nom suivant: Paul Andrew Oleskevis, vendeur, domicilie et résidant à 4444 ouest, rue Sherbrooke, app.208, en les ville et district dc Montréal, s'adressera au secrétaire dc la province afin que son nom soit changé en celui dc Paul Andrew Paul, et qu'il devra aussi concerner son épouse, Elizabeth Vowc Oleskevis (née Pcakc) sa fille, Karen Elizabeth Olcskcvis et son fils, Timothy Mark Olcskcvis, tous également domiciliés au même endroit.Le notaire du requérant, 28313-11-2 David Ahrams.Emile Pnjac/.kowski Avis est par les présentes donné que M.Emile Pajaczkowski, résidant au 11,815 rue Alexandre Lacoste, à Montréal, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en Conseil, pour l'adoption d'un décret changeant, son nom en celui de Emile Page et le nom de famille des enfants mineurs, Raymond, Daniel (Danny), Normand, et Lori-Ann, tous résidant au 11,815 rue Alexandre Lacoste, i\\ Montréal, district de Montréal, en celui de « Page » lesdits noms pour servir à toutes fins légales.Montréal, le 7 février 1969./.e procureur du requérant, 28314-1 l-2-o Y von Goulet, Avocat.Kaouf Sel i m Prenez avis par les présentes que je, Raouf Selim, m'adresserai au lieutenant-gouverneur en conseil suivant la loi (13-14 Eli.II, ch.77) pour changer mon nom île Raouf Selim en celui de Georges Selim.Montréal, le 27 février 1969.28315-11-2-0 Change of name \u2014 Act Harry Kamcnetsky Notice is hereby given tliat Harry Kamcnetsky, student, residing at 327 Alexis Niliou Blvd.] Ville St.Laurent, will apply to the lieutenant-governor in Council, for an Order changing his name to Harry Kamcn; said change of name shall also benefit his wife, née Miriam (Myra) Bloom, and his minor son, Allan Gerald, all of the same address.Montreal, March 3, 1969.Frankel & Frankei., 28311-1 l-2-o Attorneys for applicant.D'Arcy Paul Olcskcvis Notice is hereby given tliat an application will be made under the Change of Name Act 13-14 Elizabeth It, Chapter 77, requesting the following change of name: D'Arcy Paul Oleskevis Assistant Engineer, domiciled and residing at 3415 Girouard Avenue, Apt.512, in the ( ity of Montreal, District of Montreal, will apply to the Provincial Secretary to change his name to D'Arcy Paul Paul.David Abrams, 28312-11-2-0 Notary for Petitioner.Paul Andrew Oleskevis Notice is hereby given that an application will be made under the Change of Name Act 13-11 Eliz.II Chap.77, requesting the following change of name: Paul Andrew Oleskevis, Salesman, domiciled ami residing at 4444 Sherbrooke Street West, Apt.208, in the City of Montreal, District of Montreal, will apply to the Provincial Secretary to change his name to Paul Andrew Paul, and to benefit his wife, Elizabeth Vowe Olcskcvis (née Pcakc), his daughter, Karen Elizabeth Olcskcvis, and Ids son, Timothy Mark Oleskevis, all also domiciled at the same place.David AbraMB, 28313-1 l-2-o Notary for Petitioner.Emile Pujaczkowski Notice is hereby given that Emile Pajaczkowski residing at 11,815 Alexandre Lacoste, in Montreal, district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the province of Québec for adoption of an order changing his name to that of Emile Page, and the surname of his minor children Raymond, Daniel (Danny), Normand and Lori-Ann, all residing at 11,815 Alexandre Lacoste, in Montreal, district, of Montreal, to that of \"Page\" the same to avail for all legal purposes.Montreal, February 7, 1969.Y von Goulet, Advocate.28314-1 l-2-o Attorney for Claimant.Raouf Selim Take notice that I, Raouf Selim, will request the Lieutenant-Governor in council in accordance with the Act (13-14 Eli.II ch.77) to change my name from Rnouf Selim to George Selim.Montreal, February 27, 1969.28315-11-2-0 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1909, Vol.101, No.12 1849 Dcmetrious Plaskasovitou Avis est par les présentes donné que Dcmetrious Plaskasovitou, restaurateur, du 7700, 24c avenue, ville Saint-Michel, district de Montréal, s'ailressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin dc changer son nom dc James Plaskasovitou eu celui de James Spiro, et que ledit changement s'appliquera également audit Demetrious Plaskasovitou ainsi qu'il sa femme, Margaret Poulos, et à son fils, Anthony Andrew, tous de la même adresse.Donné à Montréal, le G mars 19G9.2S3G5-11-2 John M.Schlf-singer, ch.Nathan Rabinovitch Avis est par les présentes donné que Nathan Itahinovitch, administrateur, domicilié et résidant à 624, avenue Stanstcad, dans la ville de Mont-Royal, district de Montréal, s'adressera au Secrétaire dc la province afin de changer son nom en celui dc Nat Robins, qui s'appliquera à sou épouse, née Muriel Jeannette Wcissman, ménagère, et dc ses enfants mineurs non émancipés, Michael Jay, Stewart Yale et Ronald Hugh, tous domiciliés à la même place.Les procureurs du requérant, 28366-11-2 Halperin & Morris.David Rafal Il u plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 618, du 5 mars 1969, d'effectuer le changement de nom de David Itafal Kosowatsky en celui dc David Rafal.Québec^ 11 mars 1969.Ia! sous-secrétaire de la province, 28400-o Raymond Douville.Joseph George Ross Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 616, du 5 mars 1969, d'effectuer le changement de nom dc Joseph (ieorge Roscnswig en celui dc Joseph George Ross.Québec, 11 mars 1969.Le sous-secrêlaire de la province, 28400-o Raymond Douville.lin Michael Stirling Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 615, du 5 mars 1969, d'effectuer le changement dc nom dc Ludwig Antony Skuzanski en celui de Leo Michael Stirling.Québec, le 11 mars 1969./.r sous-secrétaire de la prorince, 28400-o Raymond Douville.John Crawford Bnrkc Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 617, du 11 mars 1969, d'effectuer le changement de nom dc John Crawford Boiirquc en celui de John Crawford llurke.Québec, 11 murs I960.Le sous-secrêlaire dc la province, 28400-o Raymond Douville.George Egan Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 614, du 5 mars 1969, d'effectuer le changement dc nom de Egan (Egon) lllumcnthnl en celui de George Egan.Québec, le 11 mars 1969.1*3 sous-secrêlaire dc la province, -'slOO-o Raymond Douville.Demetrious Plaskasovitou Notice is given that Demetrious Plaskasovitou restaurateur, of 7700, 24th Avenue, ville St.Michel, district of Montreal, will apply to the lieutenant-gouvcrnor in Council for an order changing his name from James Plaskasovitou to James Spiro, and that the said change benefit the said Demetrious Plaskasovitou as well as his wife, Margaret Poulos and his son, Anthony Andrew, all of the same address.Dated at Montreal, March 6, 1969.28365-11-2-0 John M.Sciilesinger, q.c Nathan Rabinovitch Notice is hereby given that Nathan Rabinovitch, executive, domiciled and residing at 624 Stonstead Avenue, in the town of Mount Royal, district of Montreal will apply to the Provincial Secretary to change his name to Nat Robins and to benefit his wife, nee Muriel Jeannette Wcissman, housewife and his unemancipatcd minor children; Michael Jay, Stewart Yale and Ronald Hugh, all domiciled at the same place.Halperin & Morris, 28366-1 l-2-o Attorneys for Petitioner.David Raful The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 618, tinted March 5, 1969, to effect the change of name of David Rafal Kosowatsky into that of David Rafal.Québec.March 11, 1909.Raymond Douville, 28100 Assistant Secretary of the Province.Joseph George Ross The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 010, dated March 5, 1909, to effect the change of name of Joseph George Roscnswig into that of Joseph (ieorge Ross.Québec, March 11, 1969.Raymond Douville, 28400 Assistant Secretary of the Province.I.e.Michael Stirling The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 015, dated March 5, 1909, to effect the change of name of Ludwig Antony Sku/.unski into that of Leo Michael Stirling.Québec, March ! 1, 1969.Raymond Douville, 28400 Assistant Secretary of the Province.John Crawford Burke The Lieutenant-Governor in Council has l>ccn pleased, by decree number 617, dated March 11, 1969, to effect the change of name of John Crawford Bourquc into that of John Crawford Burke.Québec, March 11, 1969.Raymond Douville, 28400 Assistant Secretary of the Province.George Egun The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 014, dated March 5, 1969, to effect the change of name of Egan (Egon) Blumenthal into that of George Egan.Québec, March 11, 1969.Raymond Douville, 28400 Assistant Secretary of the Province. 1850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars J9G9, 101' année, n' 12 John Joski Il u plu nu lieusenant-gouvemeur en conseil, par le décret numéro 013, du 5 mars 1969, d'effectuer le changement dc nom de John Jaworski (Jaworowski) en celui dc John .Toski.Québec, le U mars 1969.Le sous-secrêlaire île la province, 28400-o Raymond Douville.Joseph Anthony Muslro Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 019, du 5 mars 1969, d'effectuer le changement dc nom dc Giuseppe Antonio Mastromonaco en celui de Joseph Anthony Mastro.Quéln-c.le 11 mars 1969.Le sous-secrêlaire île la province, 28400-u Raymond Douville.Michel Jean Bezkorowajny Avis est par les présentes donné que Michel .lean Bc/.korownjny, décorateur, du 6510, rue Bordeaux, app.10, de la ville de Montréal, province de Québec, présentera une demande au lieiitciiant-gouverncur en conseil pour changer son nom en celui dc Michel Besko, en vertu des dis|>ositions de la Loi du changement de nom.Montréal, le S mars 1909.Le procureur du requérant, 28430-12-2 Me Sam Goldwateh.aracat.Joe \\I.,ii 11i, modifiant son territoire qui était dc la Rivière Sheldrake et dc la Rivièrc-nu-Tonnerrc en celui de la municipalité dc Rivièrc-au-Tonncrrc et la municipalité de Rivière St-.Iean, dans le district électoral dc Duplcssis.Québec, le 17 mars 1969.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies el coopêratires, 2S487-0 Ls-Philippe Bouchard.Savings and Credit Unions Caisse d'épargne et d'entraide économique des Bois-Francs (Savings and Credit Unions Act) Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law adopted on February 16, 1969 by \"La Caisse d'épargne el d'entraide économique des Bois-Francs\", amending its territory, which was that of the electoral districts of Arthabaska and Nicolct and the town of Plcssisvillc, in the electoral district of Mégantic, by extending it to the municipality of the villuge of Kingsey Falls, the municipality of Kingsey Falls or the municipality of Chutes dc Kingsey and the municipality of the township of Kingsey, in the electoral district of Drummond.Québec, March 17, 1969.Ls-Philippe Bouchahd, Deputy Minister of Financial Institutions, 28486 Companies and Cooperatives.Lu Cuisse populaire Desjardins de Hivicrc-nu-Tonnorrc (Savings and Credit Unions Act) Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law adopted on May 10, 1968 by \"La Caisse populaire Desjardins de Rivièrc-au-Tonncrrc\", amending its territory, which was that of Sheldrake River and Rivièrc-nu-Tonnerrc, to that of the municipality of Rivièrc-au-Tonncrre and the municipality of Rivière St-Jcan, in the electoral district of Duplcssis.Québec, March 17, 1969.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.2S4S7 Companies and Coopcratires. 1858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, n° 12 Liquidation \u2014 Avis de Winding up Notices Société Coopérative Agricole dc l'Acadic (Loi Syndicat National Catholique de l'Industrie du Corset \u2022le Québec\", the incorporation of which, was authorized on January 16.1939, and the head office of which is situated in Québec, and such, pursuant to section 25 of the Professional Syndicates Act, revised Statutes, 1964, chapter 146.Pursuant to paragraph ( secrétaire-trésorier, Jean-Louis Ouellet.Saint-Matiiias de Cabano Avis public est par les présentes donné par le .soussigné, secrétaire-trésorier tie la susdite municipalité, que lors dc la séance de la reprise d'ajournement tie la séance, du 10 février 1969, tenue au lieu et à l'heure ortlinaire ties séances du conseil, lundi le 17 février 1969, formant quorum et siégeant sous la présidence tic M.Armand Morcncy, maire, un règlement portant le No.140 fut atlopté, permettant la fusion tics municipalités tic la Paroisse tic St-Mathias tic Cabano à la Ville tie Cabano, créant ainsi une nouvelle municipalité tie Ville, sous le nom dc \" Ville tie Cabano » et la préparation d'une requête conjointe à soumettre au lieutenant-gouverneur à cet effet, Cette requête est déposée nu bureau du soussigné, à 173 rue Commerciale, Cabano, pour quiconque veut en prendre connaissance.Les propriétaires qui s'opposent à la fusion, peuvent dans les 30 jours, à compter tie la tlate du présent avis, faire connaître les motifs de leur opposition en s'atlrcssant par écrit à la Commission Municipale tic Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec, P.Q.Donné il Cabano, ce 24e jour tic février mil neuf cent soixante-neuf (1909).Le secrétaire-trésorier, 2S485-12-2-0 Camille-J.Leclerc.Given at Cabano, this 21st day of February, one thousand nine hundred and sixty-nine (1969)! Jean-Louis Ouellet, Secretary-Treasurer.Saint-Matiiias de Cabano Public notice is hereby given to the taxpayers of the aforementioned municipality, by the undersigned, Secretary-Treasurer of the aforementioned municipality, that at the resumption of a previously adjourned meeting, on February 10, 1969, held at the place and ordinary time of the meetings of the council, Monday, February 17, 1969, forming quorum and sitting under the presidency of Mr.Armand Morcncy, mayor, a by-law bearing No.140 was adopted,* allowing' the amalgamation of the municipalities of tlic parish of St-Mathias de Cabano to the Town of Cabano, thus creating a new town municipality, under the name of \"Town of Cabano\" and the preparing of a joint petition to be submitted to the Lieutenant-Governor to this effect.This petition is deposited at the office of the undersigned, at 173 Commerciale Street, Cabano, for whomsoever it may interest.The proprietors opposed to the amalgamation, may within 30 days, from and after the date of the present notice, make known the motives of their opposition by writing to the Quebec Municipal Commission, Government House.Québec, P.Q.Given at Cabano, this 24th tlay of February, one thousand nine hundred nntl sixty-nine (1900).Camille-.!.Leclerc, 28485-12-2 Secretary-Treasurer.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Middlesex Mutual Insurance Conipany Aris d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est tlonné, par les présentes, que « Middle, sex Mutual Insurance Company», enregistrée sous le numéro 717, a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 1919, qui l'autorise à compter du 24 janvier 1969, à effectuer dans la province ties contrats d'assurance relatifs aux genres suivants: Incendie, et accessoirement\u2014agitation civile, choc de véhicules, chute d'aéronef, défectuosité d'extincteurs automatiques, fuite d'eau, grêle, intempéries, ouragan, tremblement tie terre; Accident; Automobile; Biens immobiliers; Biens mobiliers; Bris dc glace; Bris tic machine; Chaudière à vapeur; Explosion; Responsabilité civile; Responsabilité de l'employeur; Transport intérieur; Vol.Le siège social de la compagnie est situé au 12, carré Monument, Concord, état du Massachusetts, États-Unis d'Amérique.La compagnie a nommé monsieur Mitchell Klein.1, Place Ville-Marie, Montréal, son procureur dans la province.Donné au bureau tlu Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 26 février 1969.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopêratires de la province, Le surintendant des assurances, 28303-1 l-2-o Roger-A.Camaraire.Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Middlesex Mutual Insurance Company Notice of Issue of License and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"Middlesex Mutual Insurance Company\", registered under number 717, has obtained the license and certificate of registry number 1919, authorizing it, as from the 24th of January 1969, to undertake in the province contracts of insurance of the following classes: Fire, and supplementary thereto-civil commotion, earth quake, falling aircraft, hail, impact by vehicles, spinklcr leakage, water damage, weather, windstorm; Accident; Automobile; Boiler; Employers' liability; Explosion: Inland transiiortation; Machinery; Personal property; Plate glass; Public liability; Real property; Theft.The head office of the company is situatctl a I 12, Monument Square, Concord, State of Massachusetts, United States of America.The company has appointed Mr.Mitchell Klein, 1, Place Ville Marie, Montreal, its attorney in the province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, compagnies antl cooperatives, the 26th of February, 1909.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province.Roger-A.Camaraire, 28363-11 -2-o Superintendent of Insurance. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1879 Stonewall Insurance Company Am d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné, par les présentes, que « Stonewall Insurance Company », enregistrée sous le numéro 718, a obtenu le permis et le certificat (l'enregistrement numéro 1921, qui l'autorise à compter du 29 janvier 1969, à effectuer dans la province des contrats d'assurance relatifs aux genres suivants: Accident et Maladie.Ix! siège social dc la compagnie est situé au 2:108, 4ème avenue nord, Birmingham, état dc l'Alabama, États-Unis d'Amérique.La compagnie a nommé monsieur Paul-F.Dingle, 800, carré Victoria, Montréal, son procureur dans la province.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 26 février 1969.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province.Le surintendant des assurances, 28362-1 l-2-o Roger-A.Camaraire.Stonewall Insurance Company Notice of Issue of License and Certificate Registration Notice is hereby given that \"Stonewall Insurance Company\", registered under number 718, lias obtained the license and certificate of registry number 1921, authorizing it, as from the 29th of January 1969, to undertake in the province contracts of insurance of the following classes: Accident and Sickness.The head office of the company is situated at 2308, 4th Avenue North, Birmingham, State of Alabama, United States of America.The company lias appointed Mr.Paul F.Dingle, 800, Victoria Square, Montreal, its attorney in the province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 26th of February 1969.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Rogek-A.Camakaiue, 28302-11-2-(> Superintendent of Insurance.Ministère des Richesses Department of Natural naturelles Resources Avis de révocation de droits de mine et concession minière Avis est donné par les présentes que, conformément aux articles 206, 207 et 208 dc la Loi des mines (1965, 1ère session, ch.34, modifiée par 1968, ch.30), permettant au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer les droits miniers compris dans les concessions de terre faites dans nu canton avant le 24 juillet 1880, et les concessions minières dont les lettres patentes ont été délivrées avant le 1er juillet 1911, lorsqu'aucunc exploration ou exploitation minière n'y a été faite par le propriétaire ou pour son compte durant les 10 années précédant la date de la première publication des présentes, que le ministre des Richesses naturelles recommandera au lieutenant-gouverneur en conseil la révocation des droits miniers et de la concession minière affectant les terrains ci-après désignés, après un délai de quatre-vingt-dix jours dc la deuxième publication des présentes, savoir: 1° Le lot numéro douze (12) du rang sept tVII) de l'arpentage primitif du canton d'Ascot, district électoral de Sherbrooke, correspondant aux lots numéros douzc-A, douze-B, douze-C, douze-D, douze F, douze-F, douze-G, douze-H, doiize-I.douze-.I.douzc-K, (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12b, 12i, 12j.12k) du rang sept (VII) du cadastre officiel du canton d'Ascot, district électoral et divisiond 'enregistrement de Sherbrooke.2° Le lot numéro vingt et un (21) du rang deux (II) dc l'arpentage primitif du canton dc Weedon, correspondant aux lots numéros vingt et nn-A, vingt et un-B et vingt et un-C (21a, 21b, 21c), du cadastre officiel du canton deWeedon, dans le district électoral de Wolfe.3° Concession minière pour le phosphate concédée par lettres patentes, le 16 décembre 1880, sur la moitié sud du lot numéro dix-sept (.'\u2022i S 17) du rang huit (VDII) du canton de Notice of revocation of mining rights and of mining concession Pursuant to sections 206, 207 and 208 of the mining Act (1965, 1st session, ch.34, modified by 1968, ch.36) enabling the Lieutenant-Governor in Council to revoke the mining rights included in any concession of laud made in any township before the 24th of July 1880, and the mining concessions for which letters patent were issued before the first of July 1911 when no mining exploration or operation have been made by the owner or on his behalf during the ten years preceding the date of Uic first publication of the presents, notice is hereby given to the owners of the mining rights and the mining concession of the hereunder lands that 90 days after the last publication of this notice, the Minister of Natural Resources will recommend to the Lieutenant-Governor in Council the revocation of the mining rights, and the mining concession on the following parcel of lands: 1.The lot number twelve (12) of the range seven (VII) of the original land-survey of the township of Ascot, electoral district of Sherbrooke, corresponding to lots numbers twelvc-A, twelve-B, Iwclve-C, twelvc-D, twclve-E, twelve-F, twclvc-G, twelvc-H, twelvc-I, twelvc-J, twelvc-K.(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f.12g, 121».12i, 12j, 12k) of the range seven (VII) of the official cadastre of the township of Ascot, electoral district and registration division of Sherbrooke.2° The lot number twenty-one (21) of the range two (II) of the original land-survey of the township of Weedon, corresponding to lots numbers twenty-onc-A, twenty-one-B and twen-ty-one-C (21a.21b.21c) of the official cadastre of the townsliip of Weedon.electoral district of Wolfe.3° Mining concession for phosphate granted by letters patent of December 16th, 1880, on the south-half of the lot number seventeen (}-£ S.17) of the range eight (VIII) of the townsliip of 1880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1969, 101' année, n° 12 Templeton, district électoral de Gatineau, ayant Templeton, electoral district of Gutincau, having une superficie d'environ cent acres.an area of about 100 acres.Québec, le 26 février 1909.Québec, February 26.1969.Le sous-ministre, P.-E.Auoer, 28304-1 l-2-o P.-E.Auoeh.28364-11-2-0 Deputy Minister.Régie l'électricité et du gaz Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Limited Tarif pour usage domestique Avis est, par lu présente, donné que « Anglo-Cunadian Pulp and Paper Mills Limited », distributeur d'électricité aux termes dc la Loi dc lu Régie de l'électricité et du gas, (1964, S.R.Q.chapitre 87) a, par sa requête du 13 janvier 1969, demandé ù la Régie dc l'Électricité et du Gaz d'approuver un nouveau tarif dans les limites dc la ville de Forestvillc.Tout intéressé, sur demande, peut obtenir copie du tarif proposé.Toute personne désirant soumettre des représentations concernant ladite requête devra le faire par écrit avant le 31 mars 1969.Le 12 mars 1969.Lk Secretaire.2100 rue Drummond, Montréal 107, P.Q.28434-o Electricity and Gas Board Anglo-Canadian Pulp und Paper Mills Limited Bate for domestic service Notice is hereby given that \"Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Limited\", electricity distributor as defined by the Act of the Electricity and Gas Board, (1964, R.S.Q.Chapter 87), has, by its petition of January 13, 1969, requested the Electricity anil Gas Board to approve a new rale within the city of Forestvillc limits.All concerned may obtain copy of proposed rate by request.Any person wishing to submit representations concerning said petition must do so in writing before March 31st, 1969.March 12, 1969.Secretary.2100 Drummond Street, Montreal 107, P.Q.28434-0 Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.DRUM MO N D Canada \u2014 Province de Québec District de Drummond Cour Supérieure,/J A LAURENTIENNE, No 1271.\\ ¦L-' Compagnie Mutuelle ' d'Assurance, ayant son siège social à 400 est, Grande-Allée, Québec 4, demanderesse, vs GÉRARD PERRON, domicilié ù 480, rue St-.Iean, Drummondville, défendeur.Désignation: Un emplacement situé du côté sud-est de la rue St-.Ican dans les limites de la municipalité «le Drummondville, et composé des lots suivants, savoir: a) Le lot numéro cent cinquante des subdivisions du lot originaire numéro cent quarante-sept (147-150) aux plan cl livre de renvoi du cadastre officiel du canton dc Grantham, mesurant 35.35 pieds de largeur et ayant une profondeur moyenne dc 83.83 pieds et borné comme suit: en front au nord-ouest par la rue St-.Iean, au nord-est par le lot 147-151, au sud-est par le lot 149-133, et au sud-ouest par le lot 147-149, ci-après décrit; b) Le lot numéro cent quurnntc-neuf des subdivisions du lot originaire numéro cent quarante-sept, (147-149) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton dc Grantham, mesurant 35.35 pieds dc front et ayant une profondeur moyenne dc 84.07 pieds et borné comme suit: en front au nord-ouest par la rue St-.Iean, au nord-est par le lot 147-150, au Sheriffs' Sales PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS liave been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.DRUM MOND Canada \u2014 Province of Québec District of Drummond Superior Court, (TA LAURENTIENNE No.1271.< Compagnie Mutuelle ' d'Assurance, having its head office at 400 Grande-Allée, East, Québec I.plaintiff.H GÉRARD PERRON, domiciled at 480 St-,lean St., Drummondville, defendant.Designation: An emplacement situated on the southeast side of St-,lean St.within the limits of the municipality of Drummondville, and composed of the following lots, to wit: (a) Lot number one hundred and fifty of the subdivisions of original lot number one hundred and forty-seven (147-150) on the plan and in the book of reference of the official cadastre of the township of Grantham, measuring 35.35 feel in width and having an average depth of 83.83 feet, and bounded as follows: in front, on the northwest, by St-.Iean St., on the northeast by lot 147-151, on the southeast by lot 149-133, and on the southwest by lot 147-149, hereinafter described : (b) Lot number one hundred and forty nine of the subdivisions of original lot number one hundred and forty-seven (147-149) on the ollicial plan and in the book of reference of the cadastre of the township of Grantham, measuring 35.35 feet in front and having an average depth of 84.07 fect, and bounded as follows: in front, on the northwest, by St-.Tean St., on the northeast QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1881 sud-est par le lot 149-132 et au sud-ouest par le lot 147-148 ci-après décrit; c) Le lot numéro cent quarante-huit des subdivisions du lot originaire numéro cent quarante-sept (147-148) aux plan et livre dc renvoi du cadastre officiel du canton de Grantham, mes-u rant 35.35 pieds de largeur et ayant une profondeur moyenne de 84.33 pieds et étant borné comme suit: en front au nord-ouest par la rue Sl-.Ican, au nord-est par le lot numéro 147-149, ci-dessus décrit, au sud-est par le lot 149-131 et au sud-ouest par le lot 147-147.il) l'ortie du lot numéro cent quarante-sept des subdivisions du lot originaire numéro cent quarante-sept (147 Ptie 147) aux plan et livre dc renvoi du cadastre officiel du canton dc Gran-Ihnm, mesurant 34.35 pieds dc largeur et ayant une profondeur moyenne dc 84.57 pieds, et étant borné comme suit: en front au nord-ouest par la rue St-.Iean, au nord-est par le lot 147-148 ci-haut décrit, au sud-est par le lot 149-130, et au sud-ouest par la partie restante dudit lot numéro 147-147, mesurant ladite partie restante un pied de largeur.I.c débiteur déclare que les quatre lots ci-haut mentionnés n'ont au cadastre qu'une largeur respective de 35 pieds mais que lors du bornage eu date du 12 juillet 1954 l'arpenteur monsieur Armand St-Picrre a trouvé un surplus de terrain, quel après la répartition, a donné à chacun des lots 0.35 pieds de plus monsieur Basile David étant propriétaire d'un pied sur le lot 147-147, cela explique pourquoi le débiteur a sur ce dernier lot un emplacement mesurant 34.35 pieds de largeur au lieu de 35.35 pieds.Le tout, mesure anglaise, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve de la part de l'emprunteur.Pour être vendu au bureau du shérif au Palais ¦le Justice.Drummondville, JEUDI, le VINGT-QUATRIEME jour d'AVRIL 1969 i\\ DIX heures dc l'avant-midi.Drummondville, ce 12 mars 1969.Le shirif, 28466-0 Stephen Doi.an.G ASPÉ Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Gaspé < our Provinciale, ( \"LJYDRO-QUÉBEC.corpo-No 1470.J ration légalement cons-l tituée ayant son siège social et sa principale place d'affaires au 75, ouest boulevard Dorchester, dans les ville et district -le Montréal, demanderesse, m LOUIS MARIE I.EVESQUE, résidant ù St-Joacliim dc Tourelle, comté dc Gaspé-Ouest, district dc Gaspé, défendeur.« Dc figure irrégulière, borné au nord-ouest par lis lots 10-B-lO et 10-B-9; au nord-est, au sud-est et au sud-ouest par le lot 10-B-4; mesurant cent sept pieds (107') au nord-ouest, cent vingt pieds (120') au nord-est, quatre-vingt-seize pieds (96') au sud-est, cent quatre pieds (104') au sud-ouest, contenant en superficie dix mille huit cent vingt pieds (10,820 pieds carrés), circonstances et dé|>cndances.» by lot 147-150, on the southeast by lot 149-132, and on the southwest by lot 147-148 hereinafter described; (c) Lot number one hundred and forty-eight of the subdivisions of original lot number one hundred and forty-seven (147-148) on the plan and in the book of reference of the official cadastre of the township of Grantham, measuring 35.35 feet in width and having an average depth of 84.33 feet, and being bounded as follows: in front, on the northwest, by St-.lean St., on the northeast by lot number 147-149 described above, on the southeast by lot 149-131, and on the southwest by lot 147-147.(d) Part of lot number one hundred and forty-seven of the subdivisions of original lot number one hundred and forty-seven (147-P.147) on the plan and in the book of reference of the official cadastre of the township of Grantham, measuring 34.35 fect in width and having an average depth of 84.57 feet, and bounded as follows: in front, on the northwest, by St-Iean St., on the northeast by lot 147-148 described above, on the southeast by lot 149-130, and on the southwest by the remaining part of said lot number 147-147, the said remaining part measuring one foot in width.The debtor declares that the four above-mentioned lots only have a respective width of thirty-five feet in the cadastre, but that at the time of the surveying carried out on July 12, 1954, Mr.Armand St-Pierre, land-surveyor, found an excess of land which, after repartition, gave to each of the lots 0.35 of a foot more.Since Mr.Basile David is, the proprietor of a foot on lot 147-147, that explains why the debtor has an emplacement on the last lot measuring 34.35 feet in width instead of 35.35 feet.The whole English measure, with the buildings constructed thereon, circumstances and dependencies, without exception nor reserve on the part of the borrower.To be sold in the Sheriff's Office, Court House, Drummondville, on THURSDAY, the TWENTY-FOURTH day of APRIL, 1969, at TEN o'clock in the forenoon.Drummondville, March 12, 1969.Stephen Dolan, 28466 Sheriff.GASPÉ Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Gaspé Provincial Court, ( XJYDRO-QUÉBEC, a cor-No.1470.I poration legally incor-' ponded having its head office and principal place of business at 75 Dorchester Boulevard West, in the city and district of Montreal, plaintiff, rs LOUIS MARIE LE-VESQUE, residing at St.Joachim de Tourelle, county of Gaspé-West, district of Gaspé, defendant.\"An irregular figure, bounded on the northwest by lots 10-B-10 and 10-B-9; on the northeast, southeast and southwest by lot 10-B-4; measuring one hundred and seven feet (107') on the northwest, one hundred and twenty fect (120') on the northeast, ninety-six feet (96') on the southeast, one hundred and four feet (104') on the southwest, containing in area ten thousand eight hundred and twenty feet (10,820 square feet), circumstances and dependencies\". 1SS2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1909, 101' année, n\" 12 Pour être vendu au bureau d'enregistrement «le Ste-Annc des Monts, situé au Palais de Justice demandeur, vs VIN-t CENZO SICARI el al., défendeurs.« Un emplacement situé sur le boulevard Omer-Gaucher dans la cité de Rivière-des-Prairies, et connu et désigné sous le numéro cent vingt de la subdivision du lot numéro quatre-vingt-sept (No.87-120) sur le plan et au livre de renvoi officiels de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, mesurant quarante-cinq pieds de largeur par quatre-vingt-huit pieds et quatre-vingt-quatorze centièmes dc pied de profondeur (45' x 88'.94) moins cependant, la partie de ce lot vendue au Département du Ministère de la Voirie dc la province de Québec, pour Pélargisse- Fieri Facias de 'Terris District of Montreal Montreal, to wit: ( Ti OLLAND HÉBERT, No.495 299.< *¦> plaintiff, vs VINCEN-l ZO SICARI et al., defendants.\"An emplacement situated on Omcr-Gnuchcr Boulevard in the city of Rivièrc-des-Prairics, and known and designated under number one hundred and twenty of the subdivision of lot number eighty-seven (No.87-120) on the ollicial plan and book of reference of the parish of Ri-vière-dcs-Prairies, measuring forty-five feel in width by eighty-eight feet and ninety-four hundredths of a foot in depth (45' x 88'.94) less however, the part of this lot sold to the Department of Roads of the Province of Québec, for I he enlargement of the said Boulevard, this lot now QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1885 nient dudit boulevard, ce lot étant maintenant connu comme étant la partie nord-est, bornée en front, par la partie vendue au Département du Ministère de la Voirie, en arrière, au nord-est, par le lot 87-180, d'un côté, au nord-ouest, par le lot 87-119 et de l'autre côté, au sud-est par le lot 87-121, tous des mêmes plan et livre de renvoi officiels.Tel que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit emplacement, et avec l'immeuble dessus érigé portant les numéros civiques 8651 et 8651-A, boul.Omer-(iaucher.» Pour être vendu au bureau du protonotaire (Vieux Palais de Justice) chambre no.18, 155 rue Notre-Dame est, à Montréal, le VINGT-TROISIÈME jour du mois d'AVRIL 1969, à DEUX heures de l'après-midi.Le shérif-adjoint, Bureau du Shérif, Paul St-Martin.Montréal, le 14 mars 1969.28473-0 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: ( THE PRUDENTIAL No 760 776.i 1 INSURANCE COM-l PANY OF AMERICA, demanderesse, vs JAM ES DOUGLAS McMILLAN, défendeur.« Un emplacement faisant front sur l'avenue Courtland (anciennement avenue Court), dans la ville de Dorval, se composant de la subdivision de lot numéro cinq cent douze du lot originaire numéro neuf (N° 9-512) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Lachinc; ledit lot mesure soixante pieds (60') de largeur sur quatre-vingt-dix-huit pieds (98') de profondeur, mesure anglaise.Comprenant aussi le « bungalow » séparé en bois, à un étage, qui y est érigé, et portant le numéro civique 59 dc ladite avenue Courtland.» Pour être vendus au bureau du protonotaire, au Vieux Palais de Justice, bureau 18, 155 est, rue Notre-Dame, Montréal, le VINGT-TROISIÈME jour du mois d'AVRIL 1969, à TROIS heures de l'après-midi.Le shérif-adjoint, llurcau du Shérif, Paul St-Maiitix.Montréal, le 14 murs 1969.28474 Fieri Facias dc Terris Cour Supérieure \u2014 District dc Montréul Montréal, à savoir: i OA MAJESTÉ LA REI-No 1815.\\ O NE, demanderesse, r* \\ JOS LIPARI.défendeur.« Un emplacement ayant front sur la rue St-Denis, en la cité dc Montréal, étant la moitié sud-est du lot de terre connu et désigné sous le numéro quatre cent trente-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro huit S.E.S-436) aux plan et livre de renvoi officiels du village incorporé de la Côte St-Louis, mesurant vingt-cinq pieds de largeur par une profondeur de cent trente pieds mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit: en front par la rue St-Denis, en arrière par une ruelle; d'un côté, au nord-ouest, par le résidu dudit lot No 8-436 et dc l'autre côté, au sud-est par le lot No 8-435 des mêmes plan et livre de renvoi officiels, avec les bâtisses et dépendances dessus érigées, portunt les numéros civiques, 7101, 7101a, 71016, 7103 cl 7105 de ladite rue St-Denis.» known as being the northeast part, bounded in front by the part sold to the Department of Roads, in the rear, on the northeast, by lot 87-180, on one side, on the northwest by lot 87-119 and on the other side, on the southeast by lot 87-121, all on the same official plan and book of reference.Such as the whole is presently found, with all servitudes, active and passive, apparent or occult attached to the said emplacement, and with an immovable erected thereon bearing civic numbers 8051 and 8651-A Omer-Gaucher Boulevard.\" To be sold at the Office of the Prothonotary, (Old Court House), Room No.18, 155 Notre-Dame Street East, in Montreal, on the TWENTY-THIRD day of the month of APRIL, 1969, at TWO o'clock in the afternoon.Paul St-Mabtin, Sheriff's Office, Associate Sheriff.Montreal, March 14, 1969.28473 Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: (THE PRUDENTIAL No.760 776.< i INSURANCE COM-1 PANY OF AMERICA, plaintiff, vs JAMES DOUGLAS McMILLAN, defendant.\"An emplacement fronting on Courtland Avenue (formerly Court Avenue), in the town of Dorval, composed of lot subdivision number five hundred and twelve of the original lot number nine (No.9-512), on the official plan and liook of reference of the parish of Lachinc; said lot measuring sixty feet (60') in width by ninety-eight feet (98') in depth, English measure.With the one-storey, wood, detached bungalow thereon erected bearing civic No.59 of said Courtland Avenue.\" To be sold at the Prothonotary's Office, Old Court House, Room 18, 155 Notre-Dame Street East, in Montreal, on the TWENTY-THIRD day of the month of APRIL 1969, at THREE o'clock in the afternoon.Paul St-Maiitis.Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Montreal, March 14, 1969.28474-o Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: I T-TER MAJESTY THE No.1815.< 11 QUEEN, plaintiff, rs I JOS LIPARI, defendant.\"An emplacement fronting on St-Denis Street in the city of Montreal, being the southeast half of the lot of land known and designated under number four hundred and thirty-six of the official subdivision of original lot number eight (}\u2022\u2022> S.E.8-436) on the official plan and book of reference of the incorporated village of Côte St-Louis, measuring twenty-five feet in width by a depth of one hundred and thirty feet, English measure and more or less and hounded as follows: in front on St-Denis Street, in the rear by a lane; on one side on the northwest by the remainder of said lot No.8-436 and on the other side on the southeast by lot No.8-435 on the same official plan and book of reference, with buildings and dependencies erected thereon, bearing civic numbers 7101, 7101a, 71016.7103 and 7105 of the said St-Denis Street.\" 1880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 83 mars 19G9, 101' année, n° 12 To be sold at the office of the Prothonotarv (Old Court House), Room No.18, 155 Notre-Dame Street East, in Montreal, on the TWENTY-FOURTH day of the month of APRIL, 1969, at TWO o'clock in the afternoon.Paul St-Maktin, Sheriff's Office, Associate Sheriff.Montreal, March 14, 1969.28475 Four être vendu au bureau du protonotaire (Vieux Palais de Justice) chambre No 18, 155, rue Notre-Dame est, à Montréal, le VINGT-QUATRIÈME jour du mois d'AVRIL 1969, à DEUX heures (le l'après-midi.Le shérif-adjoint, Bureau du Shérif, Paul St-Martin.Montréal, le 14 mars 1909.28475-0 NICOLET Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District dc Nicolet Cour Supérieure, ( TRUDEAU ET LAPOINTE No.3346.S a-7 LTÉE, corporation lé-v gaiement constituée ayant sa principale place d'affaires sur le Boulevard Lcmire à Drummondville, demanderesse vs RELAIS AU MOULIN ROUGE INC., corporation légalement constituée ayant sa principale place d'affaires ù St-Léonard d'Aston défenderesse et RENAUD CHAPDELAINE, régistra-leur de la division d'enregistrement dc Nicolet, mis-cn-causc.Un terrain irrégulier mesurant 648 pieds et 8/10, le long de la route Trans-Canadicnnc soit au sud-est, 323 pieds et 3/100 de pied le long dc la ligne sud-ouest, soit en suivant les sinuosités du chemin dc desserte, 425 pieds le long dc In ligne nord-ouest mesure anglaise et plus ou moins, connu et désigné comme étant une partie du lot numéro 125 du cadastre de la paroisse de St-Léonard d'Aston, comté de Nicolct, lequel terrain est borné au sud-est par la route Trans-Cana-dienne, au nord-est par la rivière Nicolet, au sud-ouest par le chemin desserte et au nord-ouest par le résidu dudit lot numéro 125.Avec les b&tissés dessus construites.La vente qui devait avoir lieu le dix-huitième jour dc février 1969, et annoncée dans la Gazelle officielle le 18 janvier 1969, aura lieu au bureau «l'enregistrement dc la division numéro 2, situé au Palais de Justice de Nicolet, district dc Nicolet, MARDI, le VINGT-DEUXIÈME jour d'AVRIL 1969, à ONZE heures dc l'avant-midi.Im shérif.Bureau du Shérif, Georges Doucet.Nicolct, ce 13 mars 1969.28481-0 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( JEAN CLAUDE GRE-Cour Supérieure J J NIER, entrepreneur-gé- No 154-769.) néral, ayant sa place d'af-' f aires à 80, rue St-Jules, Beauport, district dc Québec, M WILFRID RIOUX.domicilié à 19J4 School Street, Jewett Citv, État du Connecticut, États-Unis, et LE RÉGISTRATEUR, de la division d'enregistrement de Québec, 20, Ave Chameau, cité et district de Québec, mis-cn-cause.« 1.Un emplacement, avec maison dessus érigée et dépendances, faisant partie «lu lot (365) trois cent soixante-cinq du ea«lastre officiel «le la paroisse de St-Gabriel dc Valcartier, mesurant cent cinquante-neuf pieds dans sa ligne est, cent vingt-cinq pieds dnns sa ligne sud, cent cinquante-cinq dans sa ligne nord-ouest et cinquante pieds dans sa ligne nord, mesure NICOLET Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Nicolet Superior Court, ( TyJBEAU ET LAPOINTE No.3346.< LTÉE, body legally ' incorporated, having its head offiec on Lcmirc Blvd.in Drummondville, plaintiff, vs RELAIS AU MOULIN ROUGE INC.body legally incorporated, having its head office in St-Léonard d'Aston, defendant, and RENAl'I) CHAPDELAINE, registrar for the rcgislration division of Nicolct, mis-cn-cause.A lot of land of irregular shape, measuring 648 8/10 feet along the Trans-Canada Highway on the southeast, 323 and 3-100 fect along I he southwest line, following bends in the connecting road, 425 fect along the northwest line, English measure and more or less, known and designated as being a part of lot number 125 in the cadastre of the parish of St-Léonard d'Aston, county of Nicolet.The said lot of land is hounded on the southeast by the Trans-Canada Highway, on the northeast by the Nicolet River, on the southwest by the Chapelry road, and on the northwest by the remainder of said lot number 12\">: with the buildings constructed thereon.The sale which was to have taken place on the eighteenth day of February, 1969, and which was announced in the Official Gazelle on January is, 1969.will take place in the registry office of division No.2, situated in the Court House of Nicolet, district of Nicolct, on TUESDAY, the TWENTY-SECOND day of APRIL, 1969.at ELEVEN o'clock in the forenoon.Georges Doùcet, Sheriff's Office, Sheriff.Nicolet, March 13, 1959.284S1 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit: (JEAN CLAUDE GRE-Superior Court, J J NIER, general contrac-No.154-769.\\ tor, having his place of t business at 80 St-Jules St.Beauport, district of Québec, vs WILFRID RIOUX, domiciled at 19\"^ School St., Jewett City, State of Connecticut, United States, and THE REGISTRAR for the Québec registration division, 20 Chauveau Ave., city and district of Québec, mis-en-cause.\"1.An emplacement, with the house and dependencies erected thereon, forming part of lot (365) three hundred and sixty-five in the ollicial cadastre of the parish of St-Gabriel de Valcartier, measuring one hundred and fifty-nine fect on its east line, one hundred and twenty-five fect \"n its south line, one hundred and fifty-five feet nil its northwest line, and fifty feet on its north line, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 19(19, Vol.101, No.12 1887 anglaise; borné à l'est par un chemin, au sud au terrain de Mlle Marcelle Patry, à l'ouest et au nord au reste du terrain de M.Clément Fitz-patrick.Avec droit de passage dans le chemin à l'est pour sortir au chemin public et aussi un droit de passage dans un chemin passant au pied dc l'écart le long du lot 365-3, pour aller à la Rivière Jacques-Cartier, en commun avec les autres.Avec droit de puisage d'eau conformément au litre de M.Rioux.» « 2.Un emplacement situé en la paroisse de St-Gabriel de Valcartier, formant partie du lot connu et désigné sous le numéro (ptie 365) trois cent soixante-cinq sur le plan et dans le livre de renvoi du cadastre pour la paroisse de St-Gabriel de Valcartier, dc forme irrégulière, mesurant (63) soixante-trois pieds entre les points A et B sur le plan ci-annexé, (100) cent pieds entre les points Il et C, (125) cent vingt-cinq pieds entre les points C et D, (85) quatre-vingt-cinq pieds entre les points D et E, (187) cent quatre-vingt-sept pieds entre les points E et F, (50) cinquante pieds entre les points F et G et (150) cent cinquante pieds entre les points G et A, le tout mesure anglaise, borné au sud par le terrain dc Mlle Patry, à l'est par le terrain de l'acquéreur, au nord par le chemin dc sortie et à l'ouest partie par le terrain de monsieur Marcoux, et partie par celui de Yves Bédard et partie par celui du vendeur.Avec en plus une servitude dc passage, avec tout genre ordinaire de locomotion en faveur du lot vendu sur un chemin de vingt-cinq pieds de largeur formant partie dudit lot numéro (ptie 365) trois cent soixante-cinq cadastre dc la paroisse de St-Gabriel «le Valcartier, permettant de communiquer du lot vendu au chemin public.Ce droit de passage constituera une servitude réelle et perpétuelle sur l'assiette dudit chemin en faveur du lot vendu, et sera exercée aux risques et périls de l'acquéreur, ses héritiers et ayants cause, sans que le vendeur ne puisse être tenu à l'entretien de ce chemin.Tel que le tout est actuellement, avec les servitudes actives et passives, sans exception ni réserve.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, a Québec, le VINGT-CINQUIÈME jour d'AVRIL prochain à DIX heures de l'avant-midi.Ia: shérif-adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Mains.Québec, le 18 mars 1069.28482-o R I C II E L I E U Fieri Facia* de Terri* Canada \u2014 Province de Québec District dc Richelieu Cour Supérieure, ( TJ ÉSIDENCE FUNÉRAI-No 19-584.j iv RE A.LUSSIER LTÉE, ' corporation légalement constituée, ayant son siège social et un bureau à 148, ( ieorges.Sorel, district dc Richelieu, demanderesse, v LES HÉRITIERS DE JOSEPH BERGE-BON, en son vivant rentier, résidant à 379, East School St, Woonsocket, Rhode Island, un des états de l'Amérique du Nord, défendeur, et ROSAIRE PAQUIN.es-qualité «le régistrateur de la division d'enregistrement de Richelieu, ayant son bureau à 30, Prince, Sorel, district de Richelieu, mis-en-causc.English measure, and bounded on the cast by the road, on the south by Miss Marcelle Patry, on the west and the north by the remainder of the land belonging to Mr.Clément Fitzpatrick.With right of way on the road to the east to get to the public road, and also a right of way on a road passing at the foot of the bend along lot 365-3 to go to the Jacques-Cartier River, in common with the others.With well-sinking rights pursuant to the deed in favour of Mr.Rioux.\" \"2.An emplacement situated in the parish of St-Gabriel de Valcartier, forming part of the lot known and designated under number (P.365) three hundred and sixty-five on the plan and in the book of reference of the cadastre for the parish of St-Gabriel de Valcartier, of irregular shape, measuring (63) sixty-three fect between points A and B on the plan annexed hereto, (100) one hundred feet between points B and C, (125) one hundred and twenty-five feet between points C and D, (85) eighty-five feet between points D and E, (187) one hundred and eighty-seven fect between points E and F, (50) fifty feet between points F and G, and (150) one hundred and fifty feet between points G and A, the whole English measure, bounded on the south by the land belonging to Miss Patry, on the east by the land belonging to the purchaser, on the north by the exit road, and on the west partly by the land belonging to Mr.Marcoux, and partly by that belonging to Yves Bédard and partly by that belonging to the vendor.Also with a right of way by any ordinary means of transportation in favour of the lot sold on a road of twenty-five feet in width, forming part of said lot number (P.365) three hundred and sixty-five in the cadastre of the parish of St-Gabriel de Valcartier, permitting one to go from the lot sold to the public road.This right of way will constitute a perpetual and real servitude on the surface of the said road in favour of the lot sold, and shall be exercised at the risk and danger of the purchaser, his heirs and dependents, without the vendor's being held to maintain the said road.The whole as it is presently to be found, with the active and passive servitudes, without exception nor reservation\".To be sold in the Québec Registry Office, in Québec, on the TWENTY-FIFTH day of APRIL next at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Haixs, Sheriff's Office, Associate Sheriff.Québec.March IS, 1969.28482 RICHELIEU Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Richelieu Superior Court, I T3 ÉSIDENCE FUN ÉRAI-No.19-584.\\ RE A.LUSSIER LTÉE, \u2022 cor|m>ration legally incorporated, having its head office and an office at 148 Georges, Sorel, district of Richelieu, plaintiff, rs THE HEIRS OF JOSEPH BERGERON, in his life time annuitant residing at 379 East School Street, Woonsocket, Rhode Island, one of the United States of North America, defendant, and ROSAIRE PAQUIN.in his capacity as registrar for the Richelieu registry division, having his office at 30 Prince, Sorel.district of Richelieu, mis-en-cnuse. 1888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 mars 1969, 101' année, »° 12 « Un immeuble situé en la municipalité de la paroisse «le St-Robert, connu et désigné comme faisant partie du lot numéro deux cent sept (P.207) «lu cadastre «le ladite paroisse, mesurant un arpent «le largeur sur vingt arpents «le profondeur; le tout plus ou moins et «le mesure anglaise; tenant en front le rang Provost, en profondeur à la Concession Bellcvue, du côté d'en bas au lot No 200 dudit cadastre à Joseph Aimé Lemoinc et «lu côté d'en haut, à autre partie du susdit lot No 207 appartenant à MM.Racine et Plante; avec les bâtisses y érigées.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Sorel, à Sorel, LUNDI, le VINGT-HUITIÈME jour d'AVRIL 1909, à ONZE heures «le l'avant-midi.Le shérif, Bureau du shérif, Fhançois Gkunas.Palais dc Justice, Sorel, le 13 mars 1909.28470-o \"An immovable situated in the municipality of the parish of St-Robert, known and designated as being part of lot number two hundred ami seven (Pt 207) on the cadastre c-f the said parish, measuring one arpent in width by twenty arpents in depth; the whole more or less ami English measure; bounded in front by Provost Range, in depth by Concession Bellevue, on the lower side by lot number 200 of the said cadastre belonging to Joseph Aimé Lcmoinc and on the higher side, by another part of the above-mentioned lot number 207 belonging to Messrs.Racine and Plante; with buildings thereon erected.\" To be sold at the Sorel registry ollicc, at Sorel, MONDAY, the TWENTY-EIGHTH day of APRIL, 1969, at ELEVEN o'clock in the forenoon.François Géunas, Sheriff's Office, Sheriff.Court House, Sorel, March 13, 1909.28470 index no 12 ARRÊTÉS en Conseil ORDERS in Council 234 \u2014 Impôt sur les corporations, application «le l'article 13 (j) (Erratum).1830 234 \u2014 Corporation Tax Act, application of section 13 (j) (Erratum).1836 600 \u2014 Bois ouvré, Québec.1831 000 \u2014 Wrought wood, Québec.1831 601 \u2014 Alimentation, détail, Sherbrooke.1*27 001 \u2014 Food, Retail, Sherbrooke.1827 602 \u2014 Cercueils, Province.1829 002 \u2014 Casket, Province.1829 003 \u2014 Camionnage, Montréal.1820 603 \u2014 Cartage, Montreal.\u2022 \u2022 \u2022 \u2022 [820 004 \u2014 Bois ouvré, Québec.1820 604 \u2014 Wrought wood, Québec.1826 078 \u2014 Réserve de chasse et «le pèche de Forestvillc.1836 678 \u2014 Fish and Game Reserve of Forestvillc.1836 681 \u2014 Pro«luits laitiers, règlements.1831 681 \u2014 Dairy Products Act, regulations.1831 ASSOCIATION coopérative COOPERATIVE Association Association coopérative d'habitation co-op habitat Thibault (Formation).1850 AVIS divers MISCELLANEOUS Notices Cabano, villc-town (Requête-Pétition).|s7lJ Chevaliers «le Colomb de Temiscaming Inc., Conseil St.Theresa No 3846.1875 Conseil Colombien 6003 incorporé Lcbel-sur-Quévillon, Abitibi-Est, Québec.1875 Corporation des ingénieurs du Québec (Amendements).1876 Corporation of Engineers of Québec (Modifications).;.si'.' Knights of Columbus of Temiscaming Inc., Council St.Theresa No.3846.St-Mathias de Cabano, par.(Requête-Petition).1S,U CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME \u2014 Act Abourachid, Joe (Dcm.-Appl.).|s'.''' Bczkorowajny, Michel Jean (Dem.-Appl.).Vl Burke, John Crawford (Acc.-Grant.).VJ; Bouchard, Joseph Pierre (Acc.-Grant.).s''( Egan, George (Acc.-Grant.).SJ' Joski, John (Acc.-Grant.).Sl\" Kainenctsky, Harry (Dem.-Appl.).,sj( Mastro, Joseph Anthony (Acc.-Grant.).S|\" Oleskevis, D'Arcy Paul (Dcm.-Appl.).Oleskevis, Paul Andrew (Dem.-Appl.).s*g Fajackowski, Emile (Dem.-Appl.).}°*° Plaskasovitou, Demetrious (Dcm.-Appl.).s ; Rahinovitch, Nathan (Dcm.-Appl.).\\f™ Rafal, David Uee.-Orani.).° ; Ross, Joseph George (Acc.-Grant.).1 ' Selim, Raouf (Dem.-Appl.).,.f J*S Stirling, Leo Michael (Acc.-Grant.).'' * QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1909, Vol.101, No.12 1889 SAVINGS ami credit unions CAISSES d'épargne ct dc credit Cuisse d'épargne ct d'entraide économique des Bois-Francs (Ext.Terr.).Caisse populaire Desjardins de Rivièrc-au-Tonncrrc (La) {Ext.Terr.).1857 1857 COMPAGNIES Avis relatifs à la loi des Autorisée à faire des affaires Scwcraft Fabrics, Inc.COMPANIES Notices relative to the Act of Licensed to do Business .1851 Chartes\u2014 Charters \u2014 demandes Application for d'abandon dc Surrender of Aliard, Savage & Associates Inc.1852 Brodeur (Lachine) inc.1852 Léonard (B.) inc.1852 Oakdalc Development Corp.1852 Pavilion of Economic Progress Corporation.1851 Pavilion on the United Nations Corporation.1851 Pavillon sur les Nations Unies (Le).1851 Perry, Grant & Associates Inc.1853 Select Packers Inc.1851 Société du Pavillon dc la Vic Économique (La).1851 Suncrcst Investment Corporation.1852 Voyageurs T.P.M.inc.1852 Divers Miscellaneous llcaulnc, Charles, Fournier Évaluateurs inc.(Dir.).1853 Brodeur (Lachinc) inc.(Dût.Actif- Assets).1854 Canadian Schcnlcy Distilleries Ltd.(Dir.).1853 Carignan Assurances Inc.(Dir.).1853 Cimcx inc.(Nom-Name ch.).1855 Coq Hardi inc.(Dir.).1853 Créations Diane Paré inc.(Dir.).1853 Ferme La Cravache inc.(Dir.).1853 Gagnon (Pierre) limitée (Nom ch.).1854 Gagnon (Pierre) Limited (Name ch.) .1854 Grccnshiclds Incorporated (Dir.).1855 Grenier, Rucl & Cic inc.(Dir.).1854 Grenier, Rucl & Co.Inc.(Dir.).1854 La Salle Tricot limitée (Nom-ch.).1855 La Salle Knitting Limited (Name ch.).1855 Maroquins inc.(Les) (Dir.).1853 Miss Chinatown (South Shore) Ltd.(Dir.).1854 Samson Bélair Riddell Stead Inc.(Erratum).1854 Société VS limitée (La) (Nom-Name ch.) 1855 Soucy (.1.0.).inc.(Dir.).1854 Lettres patentes letters Patent Adlcr Development Corp.1752 Albert's Men's Wear Inc.1752 Alliance Tire (Québec) Ltd.1783 American Adventure Tours Ltd.1753 Ameublements Albert inc.1753 Animaux Canadiana inc.(Les).1753 Arbour (E.L.) inc.1754 Armabec inc.1754 Armorex inc.1754 Association des Commerçants de Chicoutimi Centre-Ville inc.(L').1755 Association des Propriétaires et Locataires du Lac Stc-Rosc.1755 Association sportive des Policiers ct Pompiers du Québec inc.1756 Astro construction inc.1756 Atelier Loisirs-Danses Victo inc.1756 Autodrome Drummond inc.1757 B.T.R.Cosmétiques inc.1757 Beaudoin transport ltée.1757 Beaugar inc.1758 Beauté Boutique inc.1758 Bersol Distributors Inc.1758 Boivin (J.Omer) & fils ltée.1759 Boulangerie Moderne Roussin ltée.1759 Boutique du Cuir inc.(La).1759 Boutique St-Charles (Trois-Rivières) ltée (La).1760 C.I.F.inc.1760 Canadiana Livestock lue.1753 Carrousel Stores Inc.1778 Centre mobile Élite inc.1760 Cercle des Fabricants du Québec inc.(La).1701 Cercle Social Féminin des Laurentides inc.1761 Chateauguay Shoe Shop Inc.1761 Ciccom Corporation.1762 Cloutier (Eugène) inc.____ 1762 Club récréatif de Montmorency inc.1762 Coaticook Harmony.1774 Cic dc gestion Sillcry inc.(La).1763 Compagnie de transport général Laberge ltée (La).1763 Conccptnt inc.1763 Confection R.D.inc.1764 Confiserie Longucuil inc.1764 Construction Norccn inc.1764 Corporation des Relations Étudiants et Administrateurs (Université Laval i 1765 Crêpe dc France (no 1) inc.(La).1705 Crêpe dc France (no 2) inc.(La).1765 Daily Cleaners and Laundcrers Ltd., .1766 Decor Plywood Ltd.1766 Dégelemcnt & Soudure dc Rivièrc-du- I .oil j i nie.1766 Desgagné construction ltée.1767 Diamond Real Estate Ltd.1767 Distributeurs Bersol inc.1758 Diversified Realties of Montreal Ltd.1767 Dominick auto-sport ltée.1768 Dominick Sport Car Ltd.- 1768 Dufour & Lapointe automobiles inc.1768 Elemcn inc.1769 Elite Picture Frames Inc.1769 Entreprises Brodeur et Lessard ltée (Les).1769 Entreprises T.M.ltée ( Les).1770 Erb-Cor Ltd.1770 Europarts Inc.1770 Fashion Converters Ltd.1771 Fédération des Clubs île Montagne du Québec inc.1771 Friday's Ltd.1771 Fuschino & associés inc.1772 Garceau et Lefebvrc inc.1772 Gémico ltée.1772 Giligon inc.1773 Gingras & Gingras limitée.1773 Hamel (Georges) inc.1773 Harmonie dc Coaticook.1774 Hélicoptères Trans-Québcc limitée (Les) 1774 I.B.S.Industrial Bearing & Supplies Ltd.1774 ICM liée.1775 Immeubles JRM inc.t.Les).1775 Immeubles Diamant ltée.1767 1890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars J9C>9, 101 \u2022 année, n° 12 Lettres patentes Letters Patent (suite) (continued) Immeubles diversifiés de Montréal ltée.1707 Immeubles Riverains ltée (Les).1775 J.L.inc.1770 ¦ltd Orange Julcp Inc.1770 Kcbcc Truck Center (1969) Ltd.1776 King of the Roast Inc.(The).1785 L.P.construction inc.1777 Lanlon inc.1777 Larin (Jacques) Entreprises inc.1777 Lenwood Products Inc.1778 Lessard Bus Lines Inc.1778 Magasins Carrousel inc.1778 Magi-Flame Inc.1779 Magi-Flammc inc.1779 Marché J.-P.Bélisle inc.1779 Mercerie Albert inc.1752 Mergl Excavation Inc.1779 Métaux Roland Roy inc.(Les).1780 Meunier (Paul) inc.1780 Montage Éclair inc.1780 Montmorcncv Diesel Inc.1781 Morin (P.A.) inc.1781 Mousseau's Limited.1781 New Miss Jean Talon Restaurant Ltd.1782 Nid du Bébé inc.(Le) .1782 Norccn Construction Inc.1764 P.A.C.E.International Inc.1782 Parent & Roy ltée.1783 Place Pointe aux Trembles inc.1783 Place Rialto inc.1783 Pneu Alliance (Québec) ltée.1783 Promotion Anjou inc.1784 R.D.R.inc.1784 Résidence Maison-Neuve ltée.1784 Restaurant La Corniche Steak House Inc.1785 Roi du Rosbif inc.(Le).1785 St.John Tools & Dies Inc.1785 St-Luc automobile inc.1786 Société d'Administration ct de Gestion des Entreprises du Croissant Vermeil inc.1786 Soeurs de la Passion de Notre-Seigneur 1786 T.M.Enterprises Ltd.1770 Tico Holding Corp.1787 Timbale Fleur de Lys inc.(La).1787 Tivoli Homes Ltd.1787 Tousignant & Associates Inc.1788 Tousignant & associés inc.1788 Trans-Québcc Helicopters Limited.1774 Tremblav (Gaétan) and Associates Insurance Ltd.1788 Tremblay (Gaétan) et associés assurances ltée.1788 33-45 inc.1789 Vari construction ltée.1788 Villager Shoe Shoppes Ltd.(The).1789 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Cardinal Furniture Industries Ltd .1790 Cité Électronique inc.1790 Contin Dyeing Ltd.1790 Gai-Mont inc.(Erratum).1790 Houle (M.C.) Auto inc.1790 Jarry Restaurant Inc.1791 LaSalle Bowling Inc.1791 Lukon Inc.1791 Morris National Sales Inc.1791 National Paint Limited.1791 Peinture Nationale limitée.1791 Presses Lithographiques (1965) inc.(Les).1792 Ross-Smith (1969) Ltd.1792 Roy (Roch) ltée.1792 Salon Fantasia inc.1792 Treasure Chest Ltd.1792 Sieges sociaux Head Offices Comett-Auto Inc.1850 Entreprises O'Conncll ltée (Les).1855 I.B.S.Industrial Bearing & Supplies Ltd.1950 New Calumet Mines Ltd.1S57 Pcrma Photo Color Inc.1855 Publications de Sexologie inc.(Les).1856 Salon Mademoiselle ltée.1856 Thibault International inc.1856 Transportcx Inc.1850 Valquin Inc.1857 DEMANDES APPLICATIONS h la Legislature to Legislature Artinian, Artin.¦.1864 Club de Golf dc Roscmere inc.1866 Compagnie Trust Royal (La).I SIM Construction d'une édifice appartements «Gratte-Ciel».1804 Construction of a « High-Risc » Apartment Building.1864 Corporation des Électroniciens du Québec (La).I8H7 ( «rte St-Luc, cité-city.1862 Église presbytérienne dc Georgetown .1863 Fédération do Montréal des Caisses Desjardins.I860 Georgetown Presbyterian Church.1803 Imperial Trust Company (The).1866 Industrial Life Insurance Company.1862 Industrielle Compagnie d'Assurance sur la Vie (L').1862 Montréal, villc-city.;.\u2022 \u2022 1867 Québec Corporation of Electronicians (The).1807 Québec, ville-city.1864 Rosemere Golf Club Inc.I860 Royal Trust Company (The).1864 Sherbrooke, cité-city.\u2022 \u2022 ¦ 1803 Société tics Traducteurs du Québec inc (La).1863 Société Nationale tic Fiducie.I860 Société St-.Iean Baptiste de Montréal.I860 Translators' Society of Québec, Inc.(The).1863 LIQUIDATION WINDING avis de \"/» Notire Société Coopérative Agricole de l'Acadic I 858 MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales Municipal Affairs Paspébiac-Ouest, munie (l'ubl.).1858 Éducation Education Municipalité scolaire de: School Municipalitu of: Aylwin (Prot.) (Acc.-Grant.).186] Côté-Nord, c.s.r.-r.s.b.(Acc.-Grant.) 1861 Des Cascades (Dem.-Appl.).I860 Laurcntienne (Dem.-Appl.).1861 Nouvellc-Acadic (Dem.-Appl.).I860 Perron Diss.(Dem.-Appl.).I860 Richelieu Valley (Prot) (Acc.-Granl.) ¦ 1861 St-David (Dem.-Appl.).1862 St-Germain, village (Dcm.-Appl.).I860 Tracadièche (Dem.-Appl.).Is1'1 Val d'Accueil (Dem.-Appl.).I860 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 22, 1969, Vol.101, No.12 1891 Institutions Financial financières.Institutions, compagnies Companies el coopératives anil Cooperatives Assurances: Insurance: Middlesex Mutual Insurance Company (Permis-License).1878 Stonewall Insurance Compuny.1879 Richesses naturelles Natural Resources Révocation de droits de mine.1879 Revocation of mining rights.1879 Terres el Forcis Lamls and Forests Cadastre: Cadastre: Parent, canton-township.1845 Ste-Dorothée, par.1845 Stc-Cencviève, par.1845 Stc-Cicneviève, par.1845 Sle-Foyc, par.1844 St-Rémi, village.1845 Stc-Thérèsc de Blainvillc, par.1845 St-Valcntin, par.1846 TRAVAIL LABOUR el dc la Main d'oeuvre and Manpower Industrie ou métiers de: Industry or Trades of: Redding & Upholstering, Province (Amend.).1841 Coiffeurs, Chicoutimi (Mod.).1839 Coiffeurs, Roberval (Mod.).1837 Directeurs de Funérailles, Ile dc Montréal ct Ile Jésus.(Prfl.).1842 Funeral Directors of the Island of Montreal and Ile Jésus (Levy).1842 Hairdressers, Chicoutimi (Amend.).1839 Hairdressers, Roberval (Amend.).1837 Literie et rembourrage.Province (Mml.) 1841 Voirie Roads Kntrelien de routes discontinué.1858 Maintenance of roads discontinued .1858 PROCLAMATIONS PROCLAMATIONS Civil marriage.1847 Division d'enregistrement de Papineau, à Papineauville.1846 Mariage civil, entrée en vigueur de la Loi 1847 Registration division of Papineau, at Papineauville.1846 RÉGIE
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.