Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 28 mars 1970, samedi 28 (no 13)
[" 102' ANNÉE VOL.102 4 quebec N° 13 1911 «fcâ /f |i^ QUEBEC OFFICIAL A Z E T T Quebec, samedi 28 mars 1970 Réglementa 1° Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7° La Gazelle officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec, a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans Me première insertion, les intéressés sont priés den aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d autre des frais onéreux de reprise.Québec, Saturday, March 28, 1970 Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gazelle is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, The Québec Official Publisher, reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, ROCH LEFEBVRE, Québec Officiai Publither 1912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102- année, n° 13 Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 35 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 15 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $4 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement: du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Roch Lefebvre.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion : 35 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 15 cents per ugutc line for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $4 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods: From January 1st to December 31st, $20; April 1st to December 31st, $15 and July 1st to December 31st, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette currying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Roch Lefedviie, Quebec Official Publisher.Hotel du Gouvernement, Québec, 30 avril 1009 33015 \u2014 1-52 I'arliument Buildings, Québec, April 30, 10G9 33015 - 1-52 Affranchissement en numeraire au tarif de lu troisième dusse (permis No 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class mutter (permit No.107).Lettres patentes Letters Patent A.A.Enterprises Inc.Les Entreprises A.A.inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: David Gregory, 218, avenue Morrison, Mont-Royal, Michael Rusko, 1390, avenue des Pins, tous deux avocats, et Paul Ostovic, homme d'affaires, 1540, avenue Sum-mcrhill, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises, sous le nom de « A.A.Enterprises Inc.\u2014 Les Entreprises A.A.inc.», avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1540, avenue Summerhil), Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785 4965-1969 Adanac électrique inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de novembre 1969, constituant en corporation: Claude Bujold, électricien, Renée Bujold, ménagère, épouse dudit Claude Bujold, tous deux de 2440, Guindon, Laval, Pierre Lefebvre, électricien, et Suzanne A.A.Enterprises Inc.Les Entreprises A.A.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 27th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: David Gregory, 218 Morrison Avenue, Mount Royal, Michael Rusko.1390 Pine Avenue, both advocates, and Paul Ostovic, businessman, 1540 Summcrhill Avenue, the latter two of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"A.A.Enterprises Inc.\u2014 Les Entreprises A.A.inc.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without par value and 3,000 preferred shares of the par value of 810 each.The head office of the company is at 1540 Sum-merhill Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-PlIILIPPE bouchaki), Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérât ires.33785-0 4965-19M Adanac électrique inc.Notice is given that under Part I ( tl'e Companies Act, letters patent, bearing dale the 28th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Claude Bujold, electrician.Hence Bujold, housewife, wife of the said Claude Bujold, both of 2440 Guindon, Laval, Pierre Lefebvre, electrician, and Suzanne Lefebvre.house- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 Lefebvre, ménagère, épouse dudit Pierre Lefebvre, ces deux derniers de 10651, St-Charles, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme électriciens et faire le commerce et l'entretien de toutes sortes d'appareils et accessoires électriques, sous le nom de « Adiinac électrique inc.», avec un capital total de > 10,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 2440, rue Guindon, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 5847-1969 Les Agences André Savard inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5c jour de janvier 1970, constituant en corporation : André Savard, représentant, Raymondc Côté, gérante, fille majeure, tous deux de 210, 94e Rue ouest, et Lionel Trottier, représentant, 5060, 5c Rue est, tous trois de Charlcsbourg, pour les objets suivants: Faire le commerce de jouets, nouveautés, ameublement, pièces décoratives, souvenirs, cadeaux et de toutes sortes de spécialités connexes, sous le nom de « Les Agences André Savurd inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 400 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie est 7335, avenue Doucct, Charlcsbourg, district judiciaire de Québec.U sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 4-1970 Association Athlétique des Employés de Dhision outaouaise (en Pontiac) de Consolidated Bathurst Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a uccordé des lettres patentes, en date du 12e jour de janvier 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Ronald Biais, opérateur, André Bellcrose, contremaître, et Jean Landry, agent, de sécurité, tous trois de Campbell's Bay, pour les objets suivants: Former et exploiter un club sportif, sous le nom «le « Association Athlétique des Employés de Division outaouaise (en Pontiac) de Consolidated Bathurst».Le mon tant auquel est limitée la valeur des hiens immobiliers, que peut acquérir et posséder la corjKiration, est de $500,000.Le siège social de la corporation est à Campbell's Bay, district judiciaire de Pontiac.U tous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.33785-0 119-70 Association de réadaptation du Québec Québec Rehabilitation Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres Patentes, en date du 27e jour de novembre 1969, 1913 wife, wife of the said Pierre Lefebvre, the latter two of 10651 St-Charles, Montreal, for the following purposes: To carry on business as electricians, and to deal in and maintain all kinds of electrical appliances and accessories, under the name of \"Adanac électrique inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common sliares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 2440 Guindon St., Laval, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 5847-1969 Les Agences André Savard inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: André Savard, representative, Raymonde Côté, manager, spinster of the full age of majority, both of 210, 94th Street West, and Lionel Trottier, representative, 5060, 5th Street East, all three of Charlesbourg, for the following purposes: To deal in toys, novelties, furniture, decorating accessories, souvenirs, gifts and all kinds of related specialties, under the name of \"Les Agences André Savard inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 400 preferred shares of $50 each.The head office of the company is at 7335 Doucet Avenue, Charlesbourg, judicial district of Québec.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 4-1970 Association Athlétique des Employés de Division outaouaise (en Pontiac) de Consolidated Bathurst Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Ronald Biais, operator, André Bellerose, foreman, and Jean Landry, security agent, all three of Campbell's Bay, for the following purposes: To organize and manage a sports club, under the name of \"Association Athlétique des Employés de Division outaouaise (en Pontiac) de Consolidated Bathurst\".The amount to which is limited the value of the immovables which may be acquired and held by the corporation is of $500,000.The head office of the corporation is at Campbell's Bay, judicial district of Pontiac.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 119-70 Association de réadaptation du Québec Québec Rehabilitation Association Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to 1914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 18 constituant en corporation sans capital-actions: Ernest O.Freedman, notaire, 374, Kitchener, Arnold F.Jones, médecin, 4360, avenue West-mount, tous deux de Wcstmount, Paul Brosseau, comptable, 37, rue Legault, Saint-Jérôme, Robert E.Meagher, rentier, 6550, Sherbrooke ouest, app.1607, Montréal, Gérard Fccteau, 9, Plage St-Laurcnt, Saint-Félix-du-Cap-Rouge, Leopold Martin, 215, Brookhaven, Dorval, Paul Mercier, 2800, Lanoraie, Sainte-Foy, et Jean Béliveau, 65, rue Victoria, Longueuil, ces quatre derniers hommes d'affaires, pour les objets suivants: Étudier les besoins et venir en aide aux handicapés, aux infirmes, aux victimes d'accidents de toutes sortes et aux malades affectés dans la motricité des différentes parties de leur corps, sous le nom de « Association de réadaptation du Québec \u2014 Québec Rehabilitation Association».Le siège social de la corporation est Édifice Sun Life, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-o 5789-69 L'Association des loisirs de Garthby et Beaulac inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de janvier 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Edmond Houde, entrepreneur, Renald Rainville, Gérard Côté, tous deux restaurateurs, Gabriel Laroche, arpenteur, et Rolland Laroche, hôtelier, tous cinq de Garthby, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de « L'Association des loisir de Garthby et Beaulac inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de 8100,000.Le siège social de la corporation est à Beaulac, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 130-1970 Association Provinciale des photographes semi-professionnels et amateurs inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Béatrix-P.Bourque, technicien, 1497, Bienville, André-G.Lemire, industriel, 374, Chatelaine, app.4, Jean-Guy Maurice, machiniste, 1101, St-Laurcnt, tous trois de Sherbrooke, et Georges Blouin, vendeur, 1180, rue Drummond, app.5, Montréal, pour les objets suivants: Grouper les photographes semi-professionnels et amateurs, sous le nom de < Association Provinciale des photographes semi-professionnels et amateurs inc.>.Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de 8100,000.incorporate a corporation without share capital; Ernest O.Freedman, notary, 374 Kitchener] Arnold F.Jones, physician, 4360 Wcstmount Ave., both of Wcstmount, Paul Brosseau, accountant, 37 Legault St., Saint-Jérôme, Robert E.Meagher, annuitant, 6550 Sherbrooke west, Apt.1607, Montreal, Gérard Fecteau, 9 Place St- Laurent, Saint-Félix-du-Cap-Rougc, Leopold Martin, 215 Brookliaven, Dorval, Paul Mercier, 2800 Lanoraie, St.Foy, and Jean Béliveau, 65 Victoria St., Longueuil, the latter four businessmen, for the following purposes: To study the needs and come to the aid of the handicapped, the lame, accident victims of all kinds and to the sick whose mobility is affected in various parts of their body, under the name of \"Association de réadaptation du Quebec \u2014 Québec Rehabilitation Association\".The head office of the corporation is in the Sun Life Building, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Puilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 5789-69 L'Association des loisirs de Garthby et Beaulac inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corjioration without share capital: Edmond Houdc, contractor, Renald Rainville, Gérard Côté, both restaurateurs, Gabriel Laroche, land surveyor, and Rolland Laroche, hotel-keeper, all five of Garthby, for the following purposes: The organization of spare time activities, under the name of \"L'Association des loisirs de Garthby et Beaulac inc.\".The amount to winch is limited the immovable property which may be acquired and owned by the corporation is 8100,000.The head office of the corporation is at Beaulac, judicial district of Saint-Grançois.Ls-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 130-1970 Association Provinciale des photographes semi-professionnels et amateurs inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a cori»ra-tion without share capital: Béatrix-P.ltoiirque, technician, 1497 Bienville, André-G.Lemire, industrialist, 374 Chatelaine, Apt.4, Jean-Guy Maurice, machinist, 1101 Saint-Laurent, all three of Sherbrooke, and Georges Blouin, salesman, 1180 Drummond Street, Apt.5, Montreal, for the following purposes: To group photographers, semi-professionals and amateurs, under the name of \"Association Provinciale des photographes semi-professioiinels et amateurs inc.\".The amount to which are limited the immovables which may be acquired and owned by the corporation is 8100,000. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 Le siège social de la corporation est à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 59-1970 Beaupré, Boucher & associés inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de janvier 1970, constituant en corporation : Henri Beaupré, avocat, 100, d'Youville, Québec, Jean-M.Boucher, comptable, Claire Desrochers, assistante comptable, épouse dudit Jcan-M.Boucher, tous deux de 3406, Place Rolland, et Jcan-P.Beaupré, publicistc, 3476A, chemin Stc-Foy, ces trois derniers de Sainte-Foy, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction, de placement, de gestion (holding) et de conseillers en administration (management consultant), sous le nom de « Beaupré, Boucher & associés inc.», avec un capital total de 340,000, divisé en 1,800 actions ordinaires de $5 chacune et en 3,100 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 100, Place d'Youville, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Prilippe Bouchard.33785-0 5995-69 Chanric inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Raymond Duquette, avocat, 350, Willowdale, app.32, Odilon Manscau, comptable, 1010, Cherricr, tous deux de Montréal, et Jacqueline Legault, secrétaire, épouse de Claude Legault, 122, Pierre Bourgery, Boucherville, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de gestion, de placement et de portefeuille, sous le nom de \u2022 Chanric inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de §10 chacune et en 3,000 aotions privilégiées de $10 chacune.I* siège social de la compagnie est 1595, rue St-Hubert, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 6317-1969 Club l'Hirondelle du Nord inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de janvier 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Robert Lefebvre, fonctionnaire, Maric-Paule Brillant, ménagère, épouse dudit Robert Lefebvre, et Paul-Éraile Plnmon-don, drilleur, tous trois de Barraute, pour les , avec un capital total de $60,000, divisé en 6,000 actions ordinaires de $10 chacune.I,e siège social de la compagnie est 500, boulevard Walberg, Dolbeau, district judiciaire de Rolierval.1$ sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.337S5-0 6354-69 ¦ Laurent Mcury inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Laurent Mcury, commerçant, Marcelle Dubois, ménagère, épouse dudit Laurent Meury, tous deux de 87, des Syndics, et Irène Desmarais, ménagère, veuve de Ovila Mcury, 4, St-Alcxis, tous trois de Salaberry-dc-Vallcyfield, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « Laurent Meury inc.», avec un capital total de $40,000 divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.l,c siège social de la compagnie est à Salabcrry-dc-YulIeyficld, district judiciaire de Beauharnois.U sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 5981-1969 Micro-Art inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Roger Plante, directeur de programmes, June Leblanc, secrétaire, épouse dudit Roger Plante, et Clément Landry, vendeur, tous trois de La Po-catière, pour les objets suivants: Faire le commerce de droits d'auteur de toutes sortes, d'oeuvres ou compositions musicales, littéraires ou autres, d'enregistrements, de feuilles de musique et d'albums, sous le nom de « Micro-Art inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.1919 The head office of the company is at Saint-Alexis, judicial district of Joliette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 6341-69 Michel Martel inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michel Martel, insurance broker, Huguette Tremblay, housewife, wife of said Michel Martel, both of 80 Walberg Boulevard, and Nicole Larocque, secretary, spinster of the full age of majority, 420, 4th Avenue, all three of Dolbeau, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers and agents, under the name of \"Michel Martel inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 6,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 500 Walberg Boulevard, Dolbeau, judicial district of Robcrval.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Mitiister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 6354-69 Laurent Meury inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Laurent Mcury, trader, Marcelle Dubois, housewife, wife of the said Laurent Meury, both of 87 des Syndics, and Irène Desmarais, housewife, widow of Ovila Meury, 4 Saint-Alexis, all three of Sala-bcrry-dc-Vallcyfield, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers and to deal in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"Laurent Meury inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Salaberry-dc-Vallcyfield, judicial district of Beauharnois.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 5981-1969 Micro-Art inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of January, 1970, liave been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Roger Plante, program director, June LcBlanc, secretary, wife of the said Roger Plante, and Clément Landry, salesman, all three of La Pocatière, for the following purposes: To deal in copyrights of all kinds, of musical, literary or other works or compositions, recordings, sheet music and albums, under the name of \"Micro-Art inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each. 1920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 88 mars 1970, 108' année, n° 13 Le siège social de la compagnie est à.La Poca-lière, district judiciaire de Kamouraska.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 6147-69 .Monuments BM inc.I .c ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Jean-Claude Gagnon, 50, Arthur Buies, Paul-Émilc Gagnon, 81, St-Jean, tous deux avocats, et Claudette l.auzicr, secrétaire, fille majeure, 314, du Rosaire, tous trois de Rimouski, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de monuments, sous le nom de « Monuments BM inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de810 chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur nominale ee 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-o 5963-69 Motel Anse au Sable inc.lx! ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26c jour de janvier 1970, constituant en corporation : Jean-Claude Gagnon, 50, boulevard Arthur Buics, Paul-Émilc Gagnon, 81, rue St-Jean, tous deux avocats, et Claudette Lauzicr, secrétaire, fille majeure, 314, du Rosaire, tous trois de Rimouski, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction et exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de «Motel Anse au Sable inc.», avec un capital total de 860,000, diivsé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 810 chacune et en 4,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe UouciiAno.33785-o 6207-1969 Multi-Nel services ltée Multi-Net Services Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Jacques Lanthier, 1470, d'Auteuil, Claude Bis-son, 237, des Sables, et Jean Saint-Jean, 525, Du-verger, tous trois industriels, de Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme nettoyeurs, blanchisseurs, teinturiers, et faire la réparation et la location de vêtements de toutes sortes, sous le nom de « Multi-Nct services ltée \u2014 Multi-Net Services Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et en 300 actions privilégiées de S100 chacune.The head office of the company is at Lu Poea-tière, judicial district of Kamouraska.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 6147-69 Monuments BM inc.Notice is given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 14th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Claude Gagnon, 50 Arthur Buies, Paul-Émilc Gagnon, 81 St-Jean, both advocates, and Claudette Lauzicr, secretary, spinster of the full age of majority, 314 du Rosaire, all three of Rimouski, for the following purposes: To manufacture and deal in monuments, under the name of \"Monuments BM inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of a nominal value uf 810 each and into 2,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Rimouski, judicial district of Rimouski.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 591)3-69 Motel Anse au Sable inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 26th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Claude Gagnon, 50 Arthur Buies Boulevard, Paul-Emile Gagnon, 81 Saint-Jean Street, both advocates, and Claudette Lauzier, secretary, spinster of the full age of majority, 314 du Rosaire, all three of Rimouski, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company and to operate hotels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Motel Anse nu Sable inc.\", with a total capital stock of 860,000.divided into 2,000 common shares of a nominal value of 810 each and 4,000 preferred shares of a nominal value of 810 each.The head office of the company is at Rimouski, judicial district of Rimouski.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 6207-1069 Multi-Net services ltée Multi-Net Services Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing (late the 23rd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Lanthier, 1470 d'Auteuil, Claude Bisson, 237 des Sables, and Jean Saint-Jean, 525 Duvcrger, all three industrialists of Laval, for the following purposes: To carry on business ns cleaners, laundrymcn, dyers and to repair and rent clothing of all kinds, under the name of \"Multi-Net services liée \u2014 Multi-Net Services Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 100 common shares of 8100 each and into 300 preferred shares of 8100 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, A'o.18 Le siège social de la compagnie est 250, boulevard des Laurentidcs, Laval, district judiciaire de Montréal.le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Pihlippb Bouchard.33785-0 387-1970 Nadon & Tremblay inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Jacques Nadon, commerçant, Carole Bcllerive, ménagère, épouse dudit Jacques Nadon, tous deux de 953, Papineau, app.2, Roger Tremblay, commerçant, 235, St-Barthélemy nord, app.2, et Michel Dionne, notaire, 776, Manseau, tous quatre de Juliette, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de machines à coudre, télévisions, dactylos, stéréo, phonographes, aspirateurs, lingerie, ameublement de maison ou de bureau et autres objets de même nature ainsi (pic leurs accessoires et parties, sous le nom de « Nadon & Tremblay inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de 81 chacune et en 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 437, rue Notre-Dame, Jolicttc, district judiciaire de Juliette.Le sous-ministre des institutions financières, companies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 6300-69 1921 The head office of the company is at 250 des Laurentides Boulevard, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 387-1970 Nadon & Tremblay inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Nadon, trader, Carole Bellerivc, housewife, wife of said Jacques Nadon, both of 953 Papineau, Apt.2, Roger Tremblay, trader, 235 St-Barthélemy North, Apt.2, and Michel Dionne, notary, 776 Manseau, all four of Jolicttc, for the following purposes: To manufacture and deal in sewing machines, televisions, typewriters, stereos, phonographs, vacuum cleaners, lingerie, house or office furnishings and other objects of the same kind as well as their accessories and parts, under the name of \"Nadon & Tremblay inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and into 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at 437 Notre-Dame Street, Joliettc, judicial district of Joliette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 6300-69 Placements Clamygo inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Claude Blouin, surveillant, 36, des Peupliers ouest, André Moisan, courtier, 244, Notre-Dame des Anges, tous deux de Québec, et Lorenzo Doyon, restaurateur, 8435, Chambery, Charlcsbourg, pour les objets suivants: Fuire affaires comme compagnie de placement, sous le nom de « Placements Clamygo inc.», avec un capital total de 860,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 6229-1969 Place St-Aimé inc.l.c ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé (les lettres patentes, en date du 5c jour de janvier 1970, constituant en corporation : Rosaire Dumais, commerçant, Rita Bouchard, ménagère, épouse dudit Rosaire Dumais, tous deux de 484, St-Bernard, Jonquière, et Jean Fortin, comptable agréé, 117, Taschercau, Kénogami, pour les objets suivants: Faire le commerce de tous produits, articles et marchandises faits en tout ou en partie de cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, Placements Clamygo inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Claude Blouin, supervisor, 36 des Peupliers West, André Moisan, broker, 244 Notre-Dame des Anges, both of Québec, and Lorenzo Doyon, restaurant-keeper, 8435 Chambery, Charlesbourg, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Placements Clamygo inc.\", with a total capital stock of 860,000, divided into 4,000 common shares of 810 each and into 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 6229-1969 Plucc Sl-.Vimé inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Rosaire Dumais, trader, Rita Bouchard, housewife, wife of said Rosaire Dumais, both of 484 St-Bcrnard, Jonquière, and Jean Fortin, chartered accountant, 117 Taschercau, Kénogami, for the following purposes: To deal in all products, articles and merchandise made wholly or partially in leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, woven 1922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n\" 13 plastique, fourrure, textiles, verre et tous sous-produits d'acier, sous le nom de « Place SI -Aimé inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $10 chacune et en 380 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 6204-69 material, glass and all steel by-products, under the name of \"Place St-Aimé inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $10 each and into 380 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 6204-69 Les productions musicales AC du Québec inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9c jour de janvier 1970, constituant en corporation: André Côté, stagiaire, 1131, chemin Ste-Foy, Québec, Diane Chouinard, épouse de Jean-Luc Chouinard, 4, Beau Site, Lauzon, et Nicole Boucher, épouse de Marcel Boucher, 7, Bisson, Saint-Romuald-d'Etchcmin, ces deux dernières secrétaires, pour les objets suivants: Faire affaires comme impresario, promoteurs ou intermédiaires pour le compte de tous genres d'artistes ou groupes d'artistes, sous le nom de < Les productions musicales AC du Québec inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 5859-69 Les productions musicales AC du Québec inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Com-panies and Cooperatives, incorporating: Andre Côté, articled student, 1131 St.Foy Road, Québec, Diane Chouinard, wife of Jean-Luc Chouinard, 4 Beau Site, Lauzon, and Nicole Boucher, wife of Marcel Boucher, 7 Bisson, Saint-Romuald-d'Etchemin, the latter two secretaries, for the following purposes: To carry on business as promotion managers or intermediaries for all types of artists or groups of artists, under the name of \"Les productions musicales AC du Québec inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares ol $100 each.The head office of the company is at Quclicc, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Fviancial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 5S59-69 J.Roland Racine inc.l.c ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Bernard Landry, avocat, 34, avenue des Sapins, #2, Alain Généreux, stagiaire en droit, 38, Lajoic nord, et Claire Sévigny, secrétaire, fille majeure, 540A, St-Antoine, tous trois de Joliette, pour les objets suivants: Exploiter des usines d'embouteillage de liqueurs douces et les systèmes de distribution requis pour ces usines et assurer la location et le commerce, sous le nom de * J.Roland Racine inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 9,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 759, De Lanaudière, Joliette, district judiciaire de Joliette.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 6149-69 Restaurant Place Royale (St-Hyacinthe) inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de janvier 1970, constituant en corporation : Dionisios Chionis, 60, rue du Roi, Sorel, Andreas Chionis, tous deux restaurateurs, et Katrine J.Roland Racine inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Bernard Landry, advocate, 34 des Sapins Avenue, #2, Alain Généreux, articled law student, 38 Lajoic north, and Claire Sévigny, secretary, spinster of the full age of majority, 504A St-Antoine, all three of Joliette, for the following purposes: To operate softdrink bottling plants and the distribution systems required by such plants, and to assure the location and business, under the name of \"J.Roland Racine inc.\", with n total capital stock of $100,000, divided into 10,000 common sliorcs of $1 each and 9,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 759 De Lanaudière, Joliette, judicial district of Joliette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératives.33785 6140-69 Restaurant Place Royale (St-Hyacinthe) inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Dionisios Chionis, 60 Du Roy Street, Sorcl, Andreas Chionis, both restaurateurs, and Katrine Tsilimidos, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 1923 Tsilimiilos, ménagère, épouse dudit Andreas Chionis, ces deux derniers de 1910, des Saules, Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom «le « Restaurant Place Royale (St-Hyacin-the) inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 6218-1969 Société Ile le m inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de janvier 1970, constituant en corporation : Joseph Bédard, entrepreneur, Lucia Drolet, ménagère, épouse dudit Joseph Bédard, tous deux de 289, boulevard Valcartier, Lorettcville, Jacques Lemieux, géographe, et Marguerite Bédard, ménagère, épouse dudit Jacques Lemieux, ces deux derniers de 15, Lambert, Saint-Romuald-d'Etchcmin, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction et de placement, sous le nom de «Société Belem inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 289, boulevard Valcartier, Lorctteville, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 6333-69 Sports Charny inc.Charny Sports Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Jean-Paul Hétu, contremaître, Laurc Bussières, ménagère, épouse dudit Jean-Paul Hétu, et Gerald Hétu, vendeur, tous trois de 2260,15c avenue est, Charny, pour les objets suivants: Faire le commerce d'articles de sports, sous le nom de « Sports Charny inc.\u2014 Charny Sports Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune et en 35,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 2260, 15e avenue est, Charny, district judiciaire de Québec.Le tous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 6357-69 Tournoi International de Hockey Midget de DrumiikiikU 111c inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province des lofi\"^ Datentes' en date ^u *6e iour de décembre 1969, constituant en corporation sans capital-actions, sous le nom de « Tournoi International housewife, wife of the said Andreas Chionis, the latter two of 1910 des Saules, Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Restaurant Place Royale (St-Hya-cinthe) inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of a nominal value of $100 each and 200 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 6218-1969 Société Belem inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Joseph Bédard, contractor, Lucia Drolet, housewife, wife of said Joseph Bédard, both of 289 Valcartier Boulevard, Lorettevillc, Jacques Lemieux, geographer, and Marguerite Bédard, housewife, wife of said Jacques Lemieux, the latter two of 15 Lambert, Saint-Romuald-d'Etchemin, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction and investment company, under the name of \"Société Belem inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 289 Valcartier Boulevard, Lorctteville, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 6333-69 Sports Charny inc.Charny Sports Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Paul Hétu, foreman, Laurc Bussières, housewife, wife of said Jean-Paul Hétu, and Gérald Hétu, salesman, all three of 2260, 15th Avenue East, Charny, for the following purposes: To deal in sports articles, under the name of \"Sports Charny inc.\u2014 Charny Sports Inc.\", with a total capital stock of §40,000, divided into 5,000 common shares of a nominal value of §1 each and into 35,000 preferred shares of a nominal value of $1 each.The head office of the company is at 2260, 15th Avenue East, Charny, judicial district of Québec.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 6357-69 Tournoi International de Hockey Midget de Dru m iikiii(1% illc inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent bearing date the 16th day of December, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating without capital shares, under tlie name of \"Tournoi International de Hockey Midget de GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 18 1924 de Hockey Midget de Drummondville inc.», les membres de la corporation « Tournoi International de Hockey Midget de Drummondville », constituée en vertu de la Loi des clubs de récréation, le ou vers le 25 mai 1965, et ce, pour les objets suivants: Établir et opérer un centre de loisirs.Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de 820,000,000.Le siège social de la nouvelle corporation est rue Cockburn, Drummondville, district judiciaire de Drummond.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 6168-69 \u20141532/21 Voyageur (1969) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour de décembre 1969, autorisant la fusion des compagnies « Provincial Transport Company \u2014 La Compagnie de Transport Provinciale » et « Provincial Transport Realties Inc.\u2014 Immeubles Transport Provincial inc.», toutes deux constituées en corporations en vertu de la première partie de la Loi des compa-pagnics, par lettres patentes en date du 22 novembre 1928 et du 30 novembre 1969 respectivement, pour les objets suivants: Faire affaires dans le transport de voyageurs et de marchandises, avec un capital action de 17,500 actions ordinaires sans valeur nominale ou valeur au pair.t Le nom de la nouvelle compagnie est « Voyageur (1969) Inc.».Le siège social de la nouvelle compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785 6337-69 \u20141532/51 Vrac-Mar inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Gilles Demers, notaire, 8, Grondin, Paul Gour-deau, 8, du Parc, tous deux de Levis, et Jean-Pierre Simard, 1626, Mon-Rcpos, Sainte-Foy, ces deux derniers industriels, pour les objets suivants: Exploiter un commerce maritime et faire affaires comme compagnie de transport, sous le nom de « Vrac-Mar inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 81 chacune et en 390 actions privilégiées d'une valeur nominale de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est au Bassin Louise, Hangar 19, Québec, district judiciaire de Québec.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 6321-69 Drummondville inc.\", the members of \"Tourne-' International de Hockey Midget de Drunimond-ville\", incorporated under the Amusement Clubs Act, on or about the 25th day of May, 1965, and such, for the following purposes: To establish and operate a recreational centre.The amount to which is limited the immovable property which the corporation may acquire and possess is 820,000,000.The head office of the new corporation is at Cockburn Street, Drummondville, judicial district of Drummond.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 6168-69\u20141532/21 Voyageur (1969) Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, authorizing the amalgamation of \"Provincial Transport Company\u2014 La Compagnie de Transport Provinciale\" and \"Provincial Transport Realties Inc.\u2014 Immeubles Transport Provincial inc.\", both incorporated under the said Part I of the Companies Act, by letters patent dated, respectively, November 22, 1928, and November 30, 1969, for the following purposes: To carry on the business of transportation of passengers and goods of all kinds, with a capital stock of 17,500 common shares without nominal or par value.The name of the new companv is \"Voyageur (1969) Inc.\".The head office of the new company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.33785-Q 6337-69\u2014153^51 Vrac-Mar inc.Notice is given Uiat under Part I of the Companies Act, letters patent bearing, date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions.Corn-panics and Cooperatives, incorporating: Gilles Demers, notary, 8 Grondin, Paul Goiirdcau, 8 du Parc, both of Levis, and Jean-Pierre Simard, 1626 Mon-Repos, St.Foy, the latter two indus-tiralists, for the following purposes: To carry on a sea-borne trade and to cany on business as a transport company, under the name of \"Vrac-Mar inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of 81 each and into 390 preferred shares of a nominal value of S100 each.The head office of the company is al Bassin Louise, Hangar 19, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératifs.33785 6321-69 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 1925 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Asbestonos Corporation Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour de décembre 1969, à la compagnie « Asbestonos Corporation Limited >, augmentant son capital par In création de 7.500 actions privilégiées de second rang d'une valeur au pair de 8100 chacune.Ix sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-e 1753-30 \u20141532/7 Asbestonos Corporation Limited Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of December, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Asbestonos Corporation Limited\", increasing its capital by the creation of 7,500 preferred second class shares of a par value of $100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 1753-30 \u2014 1532/7 Bardeaux Maibcc inc.Maibec Shingles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 31e jour de décembre 1969, à la compagnie « Bardeaux La-gueux inc.\u2014 Lagueux Shingles Inc.», constituée par lettres patentes en date du 31e jour d'août 1965, 1° changeant son nom en celui de « Bardeaux Maibec inc.\u2014 Maibec Shingles Inc.» ; 2° réduisant son capital de 840,000 à 85,000, le capital-actions annulé étant divisé en 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune; 3° augmentant son capital de 85,000 à $100,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 9,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune; 4° modifiant les dispositions ayant trait au transfert des actions.U sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.337S5-0 3880-65\u20141532/9 P.E.Boucher limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 16e jour d'août 1969, à la compagnie « P.E.Boucher limitée », 1° redésignant les actions privilégiées comme uctions privilégiées dusse « B » ; 2° augmentant son capital de $95,000 à 8195,000, par la création de 1,000 actions privilégiées classe « A ' de S100 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 2339-63\u2014 1531/108 Bardeaux Maibec inc.Maibec Shingles Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 31st day of December, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Bardeaux Lagueux inc.\u2014 Lagucux Shingles Inc.\", incor|x>rated by letters patent dated the 31st day of August, 1965, 1.changing its name to that of \"Bardeaux Maibec inc.\u2014 Maibec Shingles Inc.\"; 2.reducing its capital from $40,000 to 85,000, the annulled capital shares being divided into 3,500 preferred shares of a par value of 810 each; 3.increasing its capital from $5,000 to 8100,000, the additional capital shares being divided into 9,500 preferred shares of a par value of 810 each; 4.amending the provisions relating to the transfer of shares.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 3880-65 \u20141532/9 P.E.Boucher limitée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of August, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"P.E.Boucher limitée\", 1.redesignating its preferred shares us cluss \"B\" preferred shares; 2.increasing its capital from $95,000 to $195,000, by the creation of 1,000 class \"A\" preferred shares of $100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 2339-63 \u20141531/108 I'icrre Chouinard Assurances inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 22e jour de décembre 1969, à la compagnie « Chouinard & Lapuintc Assurances inc.», constituée par lettres patentes en date du 31e jour de mai 1968, changeant son nom en celui de « Pierre Chouinard Assurances inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 2365-68 \u2014 1531/65 Pierre Chouinard Assurances inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 22nd day of December, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Chouinard & Lapointe Assurances inc.\", incorporated by letters patent dated the 31st day of May, 1968, changing its name to that of \"Pierre Chouinard Assurances inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 2365-68 \u20141531/65 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 18 1926 Cimon Immeubles inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 2c jour de décembre 1969, à la compagnie « Cimon Immeubles inc.», étendant ses pouvoirs.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 2938-69 \u20141532/40 Clinique de l'Université Sherbrooke Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 10e jour de décembre 1969, à la corporation « Clinique de l'Université Sherbrooke», augmentant le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder ladite corporation il $80,000.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-o 2106-65 \u2014 1532/11 Clinique Kadiologiquc des Bois-Francs inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 18c jour de décembre 1969, à la compagnie « Jean-Charles Patry inc.», constituée par lettres patentes en date du 2c jour d'octobre 1968, changeant son nom en celui de « CliniqueRadiologiqucdcsBois-Francs inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.33785-0 4375-68 \u2014 1531/67 Cogec inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 9c jour de décembre 1969, à la compagnie « Domaine des Chutes inc.», constituée par lettres patentes en date du 14c jour de mai 1965, 1° changeant son nom en celui de « Cogec inc.» ; 2° augmentant son capital de $40,000 u $80,000, par la création de 4,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 2176-65\u2014 1532/41 La Compagnie Chantauteuil inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 2c jour de septembre 1969, à « La Compagnie Chantauteuil inc.», modifiant ses pouvoirs.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.33785-0 1917-68 \u2014 1532/25 Les Entreprises des Trois ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres Cimon Immeubles inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 2nd day of December, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Cimon Immeubles inc.\", extending its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératifs.33785 2938-69 \u2014 1532/40 Clinique de l'Université Sherbrooke Notice is given that under the Companies Act, the Lieutenant-Governor of the Province granted supplementary letters patent dated the 10th day of December, 1969, to ''Clinique de l'Université Sherbrooke\", increasing the amount to which is limited the value of the immovuhlc property which the said corporation may acquire and possess to $80,000.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 2106-65\u20141532-11 Clinique Kadiologiquc des Bois-Francs inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 18th day of December, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Jean-Charles Patry inc.\", incorporated by letters patent dated the 2nd day of October, 1968, changing its name to that of \"Clinique Radiologique des Bois-Francs inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérât ires.33785 4375-68\u20141531/67 Cogcc inc.Notice is given that, under Part I of tlte Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of December, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Domaine des Chutes inc.\", incorporated by letters patent dated the 14th day of May, 1965, 1.changing its name to that of \"Cogec inc.\"; 2.increasing its capital from $40,000 to $80,000, by the creation of 4,000 preferred shares of $10 each.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.33785 2176-65\u2014 1532.41 La Compagnie Chantauteuil inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 2nd day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"La Compagnie Chantauteuil inc.\", extending its powers.Ls-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératifs.33785 1917-68\u2014 1532,25 Les Entreprises des Trois ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of December, 1969, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 1927 patentes supplémentaires en date du 29e jour de décembre 1969 à la compagnie « Les Entreprises des Trois ltée», 1° diminuant son capital de $40,(100 ù $19,600, le capital-actions annulé se divisant en 2,040 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune; 2° augmentant son capital de $19,600 à $119,600, le capital-actions additionnel se divisant en 10,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Lt sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785 3990-63 \u20141532/27 Geoffrion, Robert & Gélinas, inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 17e jour d'octobre 1969 à la compagnie < Geoffrion, Holieri & Gélinas, inc.», diminuant son capital de 8104,000 à $62,000 en annulant 4,200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785 5462-45 \u2014 1532/30 GeolTrion, Robert & Gélinas eie GeolTrion, Robert & Gélinas Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 17e jour d'octobre 1969 à la compagnie « Geoffrion, Robert & Gélinas cie \u2014 Geoffrion, Robert & Gélinas Co.», diminuant son capital de $650,000 à $497,000 par l'annulation de 15,300 actions privilégiées de première catégorie d'une valeur au pair de $10 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785 13114-54 \u2014 1532/29 Gestion Hériot inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 31e jour de décembre 1969, à la compagnie « Gestion Hériot inc.», réduisant son capital de $250,000 à $25,000 par l'annulation de 250 actions ordinaires de 8100 chacune, 250 actions privilégiées classe « A » de $100 chacune, 1,745 actions privilégiées classe « B » de $100 chacune et en 5 actions privilégiées classe « C » de $100 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 4077-63 \u2014 1531/71 Gi-Mont inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 9c jour de décembre 1969, à la compagnie « Gi-Mont inc.», étendunt ses pouvoirs.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.33785-0 2917-67 \u2014 1531/100 have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Les Entreprises des Trois ltée\", 1.reducing its capital from $40,000 to $19,600, the capital stock annulled being divided into 2,040 preferred shares of the par value of $10 each; 2.increasing its capital from $19,600 to $119,600, the additional capital stock being divided into 10,000 preferred sliares of the par value of $10 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785-0 3990-63 \u2014 1532/27 Geoffrion, Robert & Gélinas, inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 17th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Geoffrion, Robert & Gélinas, inc.\", reducing its capital from $104,000 to $62,000 by the cancellation of 4,200 preferred shares of the par value of $10 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératives.33785-o 5462-45 \u20141532/30 Geoffrion, Robert & Gélinas cie GeolTrion, Robert & Gélinas Co.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 17th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Geoffrion, Robert & Gélinas cie \u2014 Geoffrion, Robert & Gélinas Co.\", reducing its capital from $650,000 to $497,000 by the cancellation of 15,300 first preferred shares of the par value of $10 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785-0 13114-54 \u2014 1532/29 Gestion Hériot inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 31st day of December, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Gestion Hériot inc.\", reducing its capital from $250,000 to $25,000 by the annulment of 250 common shares of $100 each, 250 preferred class \"A\" shares of $100 each, 1,745 preferred class \"B\" shares of $100 each and into 5 preferred class \"C\" shares of $100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 4077-63 \u20141531/71 Gi-Mont inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of December, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Gi-Mont inc.\", extending its powers.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 2917-67 \u20141531/100 i 1928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 13 Industries Maibec inc.Maibec Industries Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 31e jour de décembre 1969, à la compagnie « Lagucux & Frères inc.», constituée par lettres patentes en date du 15e jour de mars 1946, 1° changeant son nom en celui de « Industries Maibec inc.\u2014 Maibec Industries Inc.» ; 2° réduisant son capital de $350,000 à $176,370, le capital-actions annulé étant divisé en 17,363 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune; 3e augmentant son capital de $176,370 à $500,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 32,363 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune; 4° modifiant les droits afférents aux actions privilégiées; 5° ajoutant les dispositions relatives au transfert des actions.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 2804-46 \u2014 1532/14 Informations & Transactions M.C.inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 23e jour de décembre 1969, à la compagnie « Agence d'Informations civiles et commerciales inc.», constituée par lettres patentes en date du 4e jour de mars 1965, changeant son nom en celui de « Informations & Transactions M.C.inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 962-65\u2014 1531/102 M.M.P.Publicité inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 2e jour de septembre 1969, à la compagnie « Munro, Martel Publicité inc.», constituée par lettres patentes en date du 15e jour d'octobre 1968, changeant son nom en celui de « M.M.P.Publicité inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 2879-68\u20141531/106 Monette, Roger & Associés ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 9e jour de décembre 1969, à la compagnie « Monette, Thibault & Associates Ltd.\u2014 Monette, Thibault & Associés ltée », constituée par lettres patentes en date du 16e jour de juin 1969, changeant son nom en celui de « Monette, Roger & Associés ltée».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 2398-69 \u2014 1532/35 la nouvelle Compagnie Théâtrale inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplé- Industries Maibec inc.Maibec Industries Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 31st day of December, I960, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Lagueux & Frères inc.\", incorporated by letters patent dated the 15th day of March, 1946, 1.changing its name to that of \"Industries Maibec inc.\u2014 Maibec Industries Inc.\"; 2.reducing its capital from $350,000 to $176,370, the annulled capital shares being divided into 17,363 preferred shares of u par value of $10 each; 3.increasing its capitul from $176,370 to $500,000, the additional capital shares being divided into 32,363 preferred shares of a par value of $10 each; 4.amending the rights relating to the preferred shares; 5.adding the provisions relating to the transfer of shares.Ls-Phiuppe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 2804-46 \u2014 1532/14 Informations & Transactions M.C.inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 23rd day of December, 1909, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Agence d'Informations civiles et commerciales inc.\", incorporated by letters patent dated the 4th day of March.1965, changing its name to that of \"Informations & Transactions M.C.inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.33785 962-65\u20141531/102 M.M.P.Publicité inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 2nd day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Munro, Martel Publicité inc.\", incorporated by letters patent dated the 15th dav of October, 1968, changing its name to that of \"M.M.P.Publicité inc.\".Ls-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.33785 2879-68\u2014 1531/106 .Monette.Roger & Associés ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of December, 1969, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province to 'rMonctte, Thibault & Associates Ltd.\u2014 Monette, Thibault & Associés ltée\", incorporated by letters patent dated the 16th day of June, 1969, changing its name to that of \"Monette, Roger & Associés ltée\".Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institut ions.Companies and Coopérai ires.33785 2398-69\u20141532/35 La nouvelle Compagnie Théâtrale inc.Notice is given that under the Companies Act, the Lieutenant-Governor of the Province granted supplementary letters patent dated the 3rd day QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 1929 mentnires en date du 3e jour de juillet 1969, à la corporation « La nouvelle Compagnie Théâtrale inc.», augmentant le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder ladite corporation de $50,000 à $1,000,000 et étendant ses pouvoirs.Le soui-minirtre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-u 1183-65\u20141532/17 of July, 1969, to \"La nouvelle Compagnie Théâtrale inc.\", increasing the amount to which is limited the value of the immovable property which the said corporation may acquire and possess from $50,000 to $1,000,000 and extending its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institulions, Companies and Cooperatives.33785 1183-65\u20141532/17 Opérations Forestières Maibec inc.Maibec Logging Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 31e jour de décembre 1969, à la compagnie « La gueux & Thébcrge, inc.», constituée par lettres patentes en date du 21e jour de juillet 1959, 1° changeant son nom en celui de « Opérations Forestières Maibec inc.\u2014 Maibec Logging Inc.», 2° modifiant les droits afférents aux actions privilégiées; 3° augmentant son capital de $50,000 à $100,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 10,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S5 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 14299-59 \u20141532/36 Opérations Forestières Maibec inc.Maibec Logging Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 31st day of December, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Lagueux & Théberge, inc.\", incorporated by letters patent dated the 21st day of July, 1959, 1.changing its name to that of \"Opérations Forestières Maibec inc.\u2014 Maibec Logging Inc.\", 2.amending the rights attached to the preferred shares; 3.increasing its capital from $50,000 to $100,000, the additional capital shares being divided into 10,000 preferred shares of a par value of $5 each.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institulions, Companies and Cooperatives.33785 14299-59\u20141532/36 Pekuniar inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 24c jour de décembre 1969, à la compagnie « Pekuniar inc.», subdivisunt et changeant 40 actions ordinaires de $100 chacune en 4,000 actions sans valeur au pair.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 1817-68 \u20141531-104 Plow & Waiters Printing Limited Imprimerie Plow et Walters limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 30e jour de décembre 1969, à la compagnie « Plow & Waiters Holdings Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 6e jour de mai 1922, 1° changeant son nom en celui de « Plow & Watters Printing Limited \u2014 Imprimerie Plow et Watters limitée » ; 2° modifiant ses pouvoirs.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33'85 787-22\u20141532/22 Shoreland Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour de septembre 1969, à la compagnie « Shoreland Pekuniar inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of December, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Pekuniar inc.\", subdividing and changing 40 common shares of $100 each into 4,000 shares without par value.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785 1817-68 \u20141531/104 Plow & Watters Printing Limited Imprimerie Plow ct Watters limitée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of December, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Plow & Watters Holdings Ltd.\", incorporated by letters patent dated 6th day of May, 1922, 1.changing its name to that of \"Plow & Watters Printing Limited \u2014 Imprimerie Plow et Watters limitée\"; 2.modifying its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.33785-0 787-22 \u20141532/22 Shoreland Realties Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Shoreland Realties Inc.\", 1930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 88 mars 1970, 108' année, n° 18 Realties Inc., augmentant son capital par la création de 4,000 actions privilégiées classe « A » d'une valeur au pair de $100 chacune.Le sous-minislre des institulions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785 12514-56 \u20141532/49 Société de Placement R.Gervais Decary, Père & Fils, ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du lie jour de décembre 1969, à la compagnie * Rycade inc.», constituée par lettres patentes en date du 30c jour de janvier 1968, 1° changeant son nom en celui de « Société de Placement R.Gervais Decary, Père & Fils, ltée»; 2° étendant ses pouvoirs; 3° subdivisant 600 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune en 6,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune; 4° augmentant son capital de $75,000 à $200,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 94,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et en 31,000 actions privilégiées classe « B » d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 415-68 \u2014 1531/93 Société Immobilière Frontenac inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 10c jour de décembre 1969, i\\ la compagnie « Société Immobilière Frontenac inc.», étendant ses pouvoirs.Le sous-minislre des institulions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785-0 14033-60 \u2014 1532/5 Les Spécialités de Ciment et Tuile ltée Concrete Specialties and Tile Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 4e jour de décembre 1969, ù la compagnie « Les Spécialités de Ciment et Tuile ltée \u2014 Concrete Specialties and Tile Ltd.», augmentant son capital crty of Stanley Smith and to the west by the purchaser.Less: Sold from the above listed properties or parcels of land by deed registered under number 82599; (a) A certain emplacement known ns part of lot five in the first range (1 range Pt.5) on the official plan and book of reference of the township of Montcalm, county of Argenteuil, measuring one hundred feet in width by all the depth to a certain point commonly known as the \"steep rock\" and bounded; in front to the west by the public road known as route 31, on one side, to the north by part of said lot five (Pt.5) belonging to Walter Whitcomb or representatives, in the rear, to the east by the aforesaid \"steep rock and to the south by another part of five belonging to Stanley Smith or representatives; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 1947 b) Un certain lopin de terre connu comme étant une partie dudit lot cinq (P.5) aux plan et livre de renvoi officiels, mesurant dix pieds de largeur et s'étendant en profondeur du chemin public susmentionné jusqu'à Bevin's Lake, et borné: en front à l'est par le chemin public susmentionné, d'un côté, au nord, par une autre partie (P.5) appartenant à Walter Whitcomb ou représentants, à l'ouest par Bevin's Lake et de l'autre côté, au sud, par une autre partie de cinq (P- 5) appartenant à Charles A.Morrison ou représentants.Ce lopin de terre vendu est situé à une distance d'environ dix pieds au sud du chemin connu comme étant l'ancien chemin d'hiver et qui va dudit chemin public jusqu'au lac.Toutes les mesures sont mesures anglaises et plus ou moins.Taxes municipales jusqu'au 31 décembre 1969: $50.85; taxes scolaires (temporaires) jusqu'au 30 juin 1970: $25.90; frais: $9.00.Total: $85.75.Brad.Stanley, 5166, King Edward, Montréal, Québec.\u2014 Partie lot 6, rang 1, canton de Montcalm.Acte numéro 104400.Un certain lopin de terre connu et désigné aux plan ct livre de renvoi officiels du canton de Montcalm comme faisant partie du lot numéro six du premier rang (P.6, rg 1), mesurant cent vingt-cinq pieds sur ses lignes nord et sud, deux cent quatre-vingt pieds sur ses linges est ct ouest (125' x 280'); borné au nord par la propriété de Win Campbell's, au sud par la propriété de Thomas W.Cooper, à l'est par le résidu de ladite propriété appartenant au vendeur et à l'ouest par la Route numéro 31.Taxes municipales jusqu'au 31 décembre 1969: $53.71; frais: $4.00; taxes scolaires: $52.50.Total: $110.21.Alastair Latimer, 629, avenue Westluke, Montréal 267, Québec\u2014 Le lot 39 et le lot 50, bloc D, canton de Montcalm, avec bâtisses y érigées.Taxes municipales jusqu'au 31 décembre 1969: 873.69; taxes scolaires: $100.04; frais: $4.00.Total: $177.73.H.C.Forget, 238, rue Vcrchères, Ville Jacques-Cartier.\u2014 Bail du ministère des Terres et Forêts, dossier 58098.Lot 10, rang B, Lac Charette, canton de Montcalm.Tout (Irait, intérêt et privilège que l'occupant ou le détenteur d'un bail peut avoir sur ou dans le terrain et les bâtisses du lot 10, rang B, Lac Charette, canton de Montcalm.Taxes municipales jusqu'au 31 décembre 1969: $14.69; taxes scolaires jusqu'au 30 juin 1969: $15.98; frais: 84.00.Total: $34.67.Amédée Arsenault, R.R.3, Georgetown, Ontario.\u2014Bail du ministère des Terres et Forêts, dossier 59025, lot 11, rang B, canton de Montcalm.Tout droit, intérêt et privilège que peut posséder l'occupant sur et dans le terrain et les bâtisses du lot 11, rang B, Lac Charette, canton de Montcalm.Taxes municipales jusqu'au 31 décembre 1969: $18.10; taxes scolaires jusqu'au 30 juin 1969: $75.89; frais: $4.00.Total: $97.99.-Municipalité du canton de Wentworth Watson Creswell, 35 Woodridge Crescent, app.606, Ottawa 14, Ontario.\u2014Un certain lopin de l\"rÇ connu et désigné aux plan ct livre de renvoi officiels du canton de Wentworth comme étant une portion du lot numéro quatre, lettre C dans le troisième rang (P.4C, rg 3), mesurant cent pieds (100') sur chaque côté, borné à l'ouest par le nouveau chemin principal, au sud, à l'est et au nord par le vendeur, lc coin nord-ouest dudit (b) A certain piece of land known as part of said lot five (Pt.5) on the said official plan and book of reference, measuring ten feet in width and extending in depth from the aforesaid public road to Bevin's Lake, and bounded; in front to the east by the aforesaid public road, on one side, to the north by another part (Pt.5) belonging to Walter Whitcomb or representatives, to the west by Bevin's Lake and to the other side, to the south by another part of five (Pt.5) belonging to Charles A.Morrison or representatives.This parcel of land sold is situated at a distance of about ten feet south of the road known as the old winter road and which runs from the said public road to the lake.All measurements are English and more or less.Municipal tax to December 31, 1969: $50.85; school tax (Provisional) to June 30, 1970: $25.90; costs: $9.00.Total: $85.75.Brad.Stanley, 5166 King Edward, Montreal, Québec.\u2014Part lot number 6, range 1, township of Montcalm.Deed number 104400.A certain piece of land known and designated upon the official plan and in the book of reference of the township of Montcalm as forming part of lot number six in the first range (Pt.6, rg.1), measuring one hundred and twenty-five feet in the north and south lines, two hundred and eighty feet in the cast and west lines (125'x 280'); bounded north by Wm.Campbell's property, south by Thomas W.Cooper's property, east by the residue of said property pertaining to the vendor and west by the highway number 31.Municipal tax to December 31, 1969: $53.71; school taxes: $52.50; costs: $4.00.Total: $110.21.Alastair Latimer, 629 Westluke Avenue, Montreal 267, Québec\u2014 Lot 39 and lot 50, bloc D, township of Montcalm with buildings thereon.Municipal tax to December 31, 1969: $73.69: school taxes: $100.04; costs: $4.00.Total: $177.73.U.C.Forget, 238 Verchères, St.Ville Jacques-Cartier.\u2014 Department of Lands and Forests lease, file 58098.Lot 10, rang B, Lac Charette, township of Montcalm.Whatever right, interest and privilege the occupant or lease holder may possess in and to the land and buildings on lot 10, rang B, lac Charette, township Montcalm.Municipal tax to December 31,1969: $14.69; school tax to June 30, 1969: $15.98; costs: $4.00.Total: $34.67.Amédée Arseneault, R.R.3, Georgetown, Ontario.\u2014Department of Lands and Forests Lease, file 59025.Lot 11, rang B, township of Montcalm.Whatever right, interest and privilege the occupant or lease holder may possess in and to the land and buildings on lot 11, rang B, Lac Charette, township of Montcalm.Municipal tax to December 31, 1969: $18.10; school tax to June 30, 1969: $75.89; costs: $4.00: Total: $97.99.Municipality of the township of Wentworth Watson Creswell, 35 Woodridge Crescent, Apt.606, Ottawa 14, Ontario.\u2014A certain piece of land known and designated on the official plan and in the book of reference of the township of Wentworth as being a portion of lot number four, letter C in the third range (Pt.4C, Rg.3) measuring one hundred feet (100') on each side, bounded west by the main new road, south, east and north by the vendor, the northwest corner of the 1948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 13 lopin de terre vendu par les présentes est situé , ù quatre-vingt pieds (80') du coin nord-ouest de la propriété existant présentement et construite par l'acquéreur actuel sans bâtisses.Tel que ladite propriété existe présentement avec les servitudes actives et passives qui s'y rattachent.Taxes municipales ct frais: $41.41; taxes scolaires 1968/69 ct frais: $100.40; ass.provisoire 1969/70: $80.55.Total: $222.36.Leopold Côté, 144 de L'Étoile, Laval des Rapides, Ville de Laval, Québec.\u2014 Un emplacement connu et désigné comme faisant partie du lot originaire numéro un, lettre « A », dans le troisième rang, du canton de Wentworth (P.1-A, rg III), division d'enregistrement du comté d'Argcn-geuil; Borné ledit emplacement, en front vers lc nord-est, par une rue projetée étant lc lot (l-A-177-projeté), dudit canton de Wentworth, et de tous autres côtés, par des parties non subdivisés dudit lot 1-A, rang III, du canton de Wentworth.Mesurant ledit emplacement, cent pieds (100') de largeur, dans ses lignes nord-est et sud-ouest, sur une profondeur de cent pieds (100'), dans ses lignes nord-ouest et sud-est, contenant en superficie, dix mille pieds carrés (10,000 p.c), mesure anglaise, plus pu moins: La ligne sud-est dudit emplacement est parallèle à la ligne de division des cantons de Gorc ct de Wentworth et est située à une distance de huit cent pieds (800') au nord-ouest de celle-ci; La ligne nord-est dudit emplacement est perpendiculaire a la ligne de division des cantons de Gore et de Wentworth, et est située à une distance d'environ mille trois cent cinquante-trois pieds (1,353') de la ligne de division des rangs II et III dudit canton de Wentworth; cette distance étant mesurée le long de la ligne de division des cantons de Gore et de Wentworth, en allant vers le sud-ouest; Cet emplacement porte les numéros cent cinquante-neuf et cent soixante (Nos-159-160), sur un plan de subdivision projetée, préparé par Leopold Morctti, arpenteur-géomètre, en date du deux novembre, mil neuf cent soixante-quatre; Tel que lc tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit emplacement; Avec un camp d'été dessus à ûtre construit pur la Vendcresse, et avec droit de passage avec tous autres y ayant droit, dans les rues projetées communiquant audit emplacement, au lac et à la plage, mais la Venderesse ne sera pas tenue responsable d'aucun dommage pouvant découler à la suite d'accident survenu sur ces dits terrains.Taxes municipales 1969 ct frais: $34.05; taxes scolaires 1968-69 et frais: $32.78; taxes scolaires 1969-70 provisoire: $26.92.Total: $93.75.Jean-Guy Genest, adresse inconnue.\u2014 Un emplacement situé dans le comté d'Argenteuil connu et désigné comme étant composé du lot numéro quatre-vingt-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un, lettre « A » dans le troisième rang (1-A87, rg III) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, division d'enregistrement d'Argenteuil; Mesurant ledit emplacement, en arrière dans sa ligne sud, quatre-vingts pieds (80') en front, dans sa ligne nord, étant une ligne brisée dans les segments mesurant respectivement quatre pieds et soixante et onze centièmes de pieds (4.71') et soixante-dix-neuf pieds ct soixante et onze centièmes de pieds (79.71') du côté ouest, en said piece of land hereby sold is located eighty feet (80') from the north west corner of the property presently existing and built by the present purchaser without buildings thereon erected.As the said property now subsists with the active and passibe servitudes thereto attached.Municipal taxes and costs: $41,41; school taxes 1968-1969 and costs: $100.40; provisional ass 1969-1970: $80.55.Total: $222.36.Leopold Côté, 144 de l'Étoile, Laval des Rapides, Ville de Laval, Québec.\u2014An emplacement known and designated as being part of original lot number one, letter \"A\", in the third range of the township of Wentworth (P.1-A, rg.Ill), registration division of the county ol Argcnteuil; The said emplacement bounded, in front on the northeast by a planned street being lot (l-A-177-planned), of the said township of Wentworth, and on all other sides, by unsubdivided parts of said lot 1-A, range III, of the township of Wentworth.The said emplacement measuring, one hundred feet (100') in width on its northeast and southwest lines, by a depth of one hundred feet (100'), on its northwest and southeast lines, containing in area, ten thousand square feet (10,000 sq.ft.), English measure, more or less; The southeast line of the said emplacement is parallel to the division line of the townships of Gorc and Wentworth and is situated at a distance of eight hundred fect (800') on the northwest of it; The northeast line of the said emplacement is perpendicular to the division line of the townships of Gore and Wentworth, and is situated at a distance of about one thousand three hundred and fifty-three feet (1,353') from the division line of ranges II and III of the said township of Wentworth; this distance being measured along the division Une of the townships of Gorc and Wentworth, going southwest; This emplacement bears numbers one hundred and fifty-nine and one hundred and sixty (Xos.159-160), on a planned subdivision plan, prepared by Leopold Moretti, land-surveyor, dated the second day of November, one thousand nine hundred and sixty-four; As the whole is presently found, with all servitudes, active and passive, apparent or occult, attached to the said emplacement; With a summer camp to be built thereon by the vendor, and with a right of way with all others having a right thereto, on the planned streets communicating to the said emplacement, to the lake and beach, but the vendor will not be held responsible for any damage which may result from an accident occuring on the said lands.Municipal taxes 1969 and costs: $34.05; school taxes 1968-69 and costs: $32.78; school taxes 1969-70 provisional: $26.92.Total: $93.75.Jean-Guy Genest, address unknown.\u2014 An emplacement situated in the county of Argcnteuil known and designated as being composed of lot number eighty-seven of the official subdivision of original lot number one, letter \"A\" in the third range (1-A87, rg.Ill) on the official plan and book of reference of the township of Wentworth, registration division of Argenteuil; The said emplacement measuring, in the rear on its south line, eighty feet (80') in front, on its north line, being a broken line on the segments measuring respectively four feet and seventy-one hundredths of a foot (4.71') and seventy-nine feet and seventy-one hundredths of n foot (79.71') on the west side, in depth, one hundred QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 1949 profondeur, cent quarante-cinq pieds et cinquante-neuf centièmes (145.59') de pieds, et du côté est, en profondeur également, cent dix-neuf pieds ct cinquante-cinq centièmes de pieds (119.55') le tout formant une superficie totale de dix mille six cent soixante-treize pieds carrés (10.673 ]).c), mesure anglaise, plus ou moins; Tel que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit emplacement; Le tout sans bâtisse; avec droit de passage avec tous autres y ayant droit, dans les rues projetées communiquant audit emplacement, aux lacs, à la piscine et aux plages, mais la venderesse ne sera pas tenue responsable d'aucun dommage pouvant découler à la suite d'accident survenu sur cesdits terrains.Taxes municipales 1969 et frais: 84.66; taxes scolaires 1968-69 et frais: $5.05; taxes scolaires 1969-70 provisoire: $3.61.Total: 813.32.Emile Jutras, 5345 Des Maçons, Pierrefonds, Roxboro 920, Québec.\u2014 Un emplacement vacant située dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant la partie est du lot numéro quarante-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro un, lettre « A » (1-A Ptie E 49, rg III), dans le troisième rang du canton de Wentworth, division d'enregistrement d'Argenteuil; Mesurant ladite partie de lot, cinquante pieds (50') de largeur, en front, dans sa ligne nord, étant un chemin (l-A-54), et cinquante pieds (50') en arrière, dans sa ligne sud, sur une profondeur de cent pieds (100') dans sa ligne ouest, ct cent pieds (100') également, dans sa ligne est, formant une superficie totale de cinq mille pieds carrés (5,000 p.c.) mesure anglaise, plus ou moins; Borné en front, du côté nord, par une rue (l-A-54), en arrière, du côté sud, par une partie des lots l-A-36 et l-A-35, du côté est, par le lot l-A-50, ct du côté ouest, par le résidu dudit lot l-A-49, tous dudit cadastre officiel du canton de Wentworth ; Tel que le tout se trquve présentement, avec tous les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit emplacement; Le tout sans bâtisse; avec droit de passage avec tous autres y ayant droit, dans les rues projetées communiquant audit emplacement, aux lacs, à la piscine et aux plages, mais la venderesse ne sera pas tenue responsable d'aucun dommage pouvant découler à la suite d'accident survenu sur cesdits terrains; Taxes scolaires 1968-69 et frais: $7.05; taxes scolaires 1969-70 provisoire: 83.61.Total: $10.66.and forty-five feet and fifty-nine hundredths of a foot (145.59'), and on the east side, also in depth, one hundred and nineteen feet and fifty-five hundredths of a foot (119.55') the whole forming a total area of ten thousand six hundred and seventy-three square feet (10,673 sq.ft.), English measure, more or less; As the whole is presently found, with all servitudes, active and passive, apparent or occult, attached to the said emplacement; The whole without buildings; with a right of way with all others allowed, on the planned streets communicating from the said emplacement to the lakes, pools and beaches, but the vendor will not be held responsible for any damage which may result from accidents occuring on the said lands.Municipal taxes 1969 and costs: $4.66; school taxes 1968-69 and costs: $5.05; school taxes 1969-70 provisional: $3.61.Total: $13.32.Emile Jutras, 5345, des Maçons, Pierrefonds, Roxboro 920, Québec.\u2014 A vacant emplacement situated in the county of Argenteuil, known and designated as being the east part of lot number forty-nine of the official subdivision of original lot number one, letter \"A\" (1-A P.-E.49 rg.ni), on the third range of the township of Wentworth, registration division of Argenteuil; The said part of lot measuring fifty feet (50') in width in front, on its north line, being a road (l-A-54), and fifty feet (50') in the rear, on its south line, by a depth of one hundred feet (100') on its west line, and one hundred feet (100') also, on its east line, forming a total area of five thousand square feet (5,000 sq.ft.), English measure, more or less; Bounded in front, on the north side, by a street (l-A-54), in the rear, on the south side, by a part of lots l-A-36 and l-A-35, on the east side by lot l-A-50, and on the west side by the remainder of said lot l-A-49, all of the said official cadastre of the township of Wentworth; As the whole is presently found, with all servitudes, active and passive, apparent or occult, attached to the said emplacement; The whole without buildings; with a right of way with all others allowed, on the planned streets communicating from the said emplacement to the lakes, the pools and beaches, but the vendor will not be held responsible for any damage which could result from an accident occuring on the said lands.School taxes 1968-69 and costs: $7.05; school taxes 1969-70 provisional: $3.61.Total: $10.66.Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard Mme Claude Reis, 115 Hickson, St.Lambert, Québec\u2014 Contrat 82048, septembre 1956.Lot 13B, rang I aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil, avec bâtiment.Superficie 22 acres.Taxes municipales ct frais: $104.14.Charles L.Eldon, 4823 Pierre Lauzon, Pierre-fonds.\u2014 Contrat 106645, août 1964.Lot 24A-3, rang II, aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil, avec bâtiment.Droit de passage sur lot 24A-2-3, 24A-14 et partie 24A pour chemin public et 24A-2-2 sur la plage.Superficie 2728.Taxes municipales et frais: $129.28; taxe scolaire et frais: $188.65.Total: $317.93.Mlle Jean Anne Valérie Donnison, 3657 rue Duroeher, Montréal, Québec\u2014Contrat 92976, octobre 1960.Municipality of Saint-Adolphe d'Howard Mrs.Claude Reis, 115 Hickson, Saint-Lambert, Québec\u2014 Deed 82048, September, 1956.Lot 13B, range I on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil, with a building.Area 22 acres.Municipal taxes and costs: $104.14.Charles L.Eldon, 4823 Pierre Lauzon, Pierre-fonds\u2014Deed 106645, August, 1964.Lot 24A-3, range II, on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil, with a building.A right of way on lot 24A-2-3, 24A-14 and part 24A for the public road and 24A-2-2 on the beach.Area 2728.Municipal taxes and costs: $129.28; school taxes and costs: $188.65.Total: $317.93.Miss Jean Anne Valérie Donnison, 3657 Duro-cher Street, Montreal, Québec\u2014 Deed 92976, October 1960. 1950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n\" 18 Lot 14-1, 15-36, rang III.Terrain 55 pieds de large sur la route, 115 pieds à l'arrière, 160 pieds ligne ouest en profondeur, 122 pieds ligne est en profondeur.Superficie 10758 pi.c.Subdivision lot 14-1 rang III, 87 pieds de large, ligne nord-est, 115 pieds largeur sud-est, 29.8 pieds profondeur ligne est, 108 pieds profondeur ligne ouest.Superficie 6026 pi.c.Subdivision 15-36, rang III, 55 pieds largeur ligne nord, 87 pieds largeur ligne sud-ouest, 92.2 pieds profondeur ligne est, 52 pieds profondeur ligne ouest.Superficie 4732 pieds carrés.Taxes municipales et frais: $17.41; taxes scolaires et frais: $8.38.Total: $25.79.Huro Inc., 274, rue Barette Saint-Jérôme, Québec\u2014 Contrat 132386, janvier 1970.Lot 4-19, rang II.Subdivision 19 du lot originaire 4, rang II aux plan ct livre de renvoi officiel du canton Howard, comté Argenteuil.Taxes scolaires et frais: $16.18.Denise Brodeur, adresse inconnue.\u2014Contrat 120426, août 1967.Lot 14, subdivisions 47 à 51, rang III; Lot 14 S.47, superficie 8803; Lot 14 S.48 superficie 8700; Lot 14 S.49 superficie 8415; Lot 14 S.50 superficie 9600; Lot 14 S.51 superficie 9600; Superficie totale 45118, aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Taxes municipales et frais: $77.55; taxes scolaires ct frais: $107.36.Total: $184.91.Adolf Schwackc, 12520 Pacific Ave., apt.21, cité de Mar Vista, Cal.U.S.A.a/s Franco Bar-beris, 3624 boulevard Décarie, Montréal.\u2014Contrat 117196 décembre 1966.Lot 15, subdivision 67, rang III, aux plan et livre de renvoi officiel du canton d'Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 11719.Taxes municipales et frais: $126.32; taxes scolaires et frais: $230.69.Total: $357.01.Joe Ostogic, 6776A Louis Hémon Montréal, Québec.\u2014 Lot 26, subdivision 20, rang III.Aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 7900 pieds carrés.Intervention: Denise Gauthier.Taxes scolaires et frais: $23.83; taxes municipales et frais: $11.17.Total: $35.00.Arthur Groleau, 10 Brien, Laval des Rapides, Québec\u2014Contrat 123621, mai 1968.Lot 26, subdivision 33, rang III.Aux plan ct livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 8966 pieds carrés.Taxes scolaires et frais: $142.88; taxes municipales ct frais: $113.58.Total: $256.46.Aspell Ranch, Saint-Adolphe d'Howard.\u2014 Contrat 125672, août 1968.Lot 32, subdivision 80, rang III; lot 32, subdivision 81, rang III; lot 82-Pt.rang III, lot 32 subdivision 84, rang III aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 48,000 pieds carrés.Taxes municipales et frais: $129.65.Mme Brigitte Schulz Steenneckg (Poppen-buttel) Schulbergredder 22, Hambourg, Allemagne\u2014Contrat 104759, mars 1964.Lot 21, subdivision 8, rang IV aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 18,775 pi.c.Taxes scolaires et frais: $56.30; taxes municipales et frais: $43.58.Total: $99.88.Mathilda Lulic, épouse de Yvan Vidicek, 447A, 67e Avenue, Chomedey, Laval.\u2014Contrat 106725, août 1964.Lot 5, subdivision 37, rang V aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté Lot 14-1, 15-36, range HI.A piece of land ol 55 feet in width on the route, 115 feet in the rear, 160 feet on a west line in depth 122 feet on an east line ineadepth.Area 10758 square feet.Subdivision lot 14-1 range III, 87 feet in width, the northeast line 115 feet in width south-cast 29.8 feet in depth east line, 108 feet in depth on the west line, area 6026 square feet.Subdivision 15-36, range III, 55 feet in width on the north line, 87 feet in width on the southwest line, 92.2 feet in depth on the east line, 52 feet in depth on the west line.Area 4732 square feet.Municipal taxes and costs: $17.41; school taxes and costs: $8.38.Total: $25.79.Huro Inc., 274 Barrette Street, Saint-Jérôme, Québec\u2014Deed 132386, January, 1970.Lot 4-19, range II.Subdivision 19 of original lot 4, range II on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.School taxes and costs: $16.18.Denise Brodeur, address unknown.\u2014 Deed 120426, August, 1967.Lot 14, subdivisions 47 to 51, range III; Lot 14 S.47 area 8803; Lot 14.S.48 area 8700; Lot 14.S.49 area 8415; Lot 14.S.50 area 9600; Lot 14.S.51 area 9600.Total area 45118, on the official plan and hook of reference of the township of Howard, county of Argcnteuil.Municipal taxes and costs: S77.55; school taxes and costs: $107.36.Total: $184.91.Adolf Schwacke, 12520 Pacific Avenue Apt.21, city of Mar Vista, Cal., U.S.A., c/o Franco Barbe-ris, 3624 Decarie Boulevard, Montreal.\u2014 Deed 117196, December, 1966.Lot 15, subdivision 67, range III, on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Area 11719, Municipal taxes and costs: $126.32; school taxes and costs: $230.69.Total: $357.01.Joe Ostogic, 6676A, Louis Hémon, Montreal, Québec.\u2014 Lot 26, subdivision 20, range III, on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argcnteuil Area 7900 square feet intervention : Denise Gauthier.Municipal taxes and costs: $11.17; school taxes and costs: $23.83.Total: $35.00.Arthur Groleau, 10 Brien, Laval des Rapides, Québec\u2014Deed 123621, May, 1968.Lot 26, subdivision 33, range III, on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argcnteuil.Area 8966 square feet.Municipal taxes and costs: S113.5S; school taxes and costs: $142.88.Total: $256.46.Aspell Ranch, Sainte-Adolphe d'Howard \u2014 Deed 125672, August, 1968.Lot 32, subdivision 80, range HI; lot 32, subdivision 81, range III; lot 82 P.range III.lot 32 subdivision 84, range III on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Area 48,000 square feet.Municipal taxes and costs: $129.65.Mrs.Brigitte Schulz Steenneckg, (Poppen-buttel) Schulbergredder 22, Hamburg, Germany.\u2014 Deed 104759, March, 1964.Lot 21, subdivision 8, range IV on the official plan and book of reference of the township o« Howard, cuunty of Argenteuil.Area .1^,775 square feet.Municipal taxes and costs: S43.oS; school taxes and costs: $56.30.Total: 899.SS.Mathilda Lulic, wife of Yvan Vidicck, 44/A.67th Avenue, Chomcdey, Laval.\u2014Deed 10672a, August, 1964.Lot 5, subdivision 37, range V on the oracial plan and book of reference of the township of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 1951 d'Argenteuil.Superficie 14,928 pieds carrés.Taxes scolaires et frais : $106.66; taxes municipales et frais: $67.79.Total: $174.45.Brigitte Ruth (Godin) Wolpert, Woldker-chcrstmsse 8, Freiburg, Brusgau, Germany.\u2014 Contrat 117000, novembre 1966.Lot 4, subdivision 5, rang V, lot 5, subdivision 54, rang V aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 11,385 pieds carrés.Taxes municipales ct frais: $10.93; taxes scolaires et frais: $3.20.Total: $14.13.Domaine Howard Ltée., (faillite, dossier 815) L.Claude Mercure Syndic, 804 Tour de la Bourse, Montréal, Québec\u2014Contrat 122339, janvier 196S.Lots 1-A subdivision 11-1 à 11-13, rang VI et 2-A, subdivision 11, rang VI aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Bornes nord-est Lac St.Joseph, sud-est par une partie de partie non subdivisé du lot originaire 1-A, sud-ouest par une partie non subdivisée des lots 1-A-ll et 2-A, nord-ouest par le lot 2-A-10.Superficie 82,641 pieds carrés.Taxes municipales et frais: $3,305.87; taxes scolaires et frais: $7,682.37.Total: $10,988.24.Lucien Chastenais, 9870,63e Avenue, Rivière des Prairies\u2014Contrat 107777, octobre 1964.Lot 7, subdivisions 112, 113, 114, 115, rang VI aux plan ct livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 10,000 pieds carrés.Taxes municipales et frais: $12.40; taxes scolaires ct frais: $16.58.Total: $28.98.Jean Gagnon, 9670, 70e Avenue, Rivière des Prarics.\u2014Contrat 104183, décembre 1963.Lot 7, subdivisions 339 à 342, rang VI ct lot 8, subdivisions 376, rang VI aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 10,000 pieds carrés.Taxes municipales ct frais: $12.40; taxes scolaires et frais: $13.07.Total: $25.47.Pierrette Benoit, 10770 Vianncv, Montreal, Québec.\u2014Contrat 104371, janvier 1964.Lot 7, subdivisions 369, 370 et 371, rang VI aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil Superficie 7,500 pieds carrés.Taxes municipales et frais: $9.69; taxes scolaires et frais: $5.71.Total: $15.40.Daniel Bcrtone, 3135 boulevard Langclier, Montréal, Québec\u2014Contrat 118366, mars 1967.Lot 7, subdivisions 389, 390 et 391 rang VI aux plan ct livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 7,500.Taxes municipales et frais: $9.84; taxes scolaires et frais: $5.71.Total: $15.55.Edouard Labbé, 5200, 3c avenue, apt.4, Montreal.\u2014Lot 7, subdivisions 693, 694 695 et 696, rang VI aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 10,000 pieds carrés.Taxes municipales et frais: $15.36; taxes scolaires ct frais: $16.58.Total: $31.94.Maurice Bordeleau, 4705 Hochelaga, apt.3, Montréal.\u2014 Contrat 98790, juillet 1962.Lot 7, subdivision 908, rang VI aux plan ct uyre de renvoi officiel du canton Howard, comté dArgenteuil.Superficie 13,400 pieds carrés.Taxes municipales ct frais: $16.49; taxes scolaires et frais: $27.94.Total: $44.43.Paul Dionnc cède à Jacques Lefebvre, 11785 loutrincourt, Montreal.\u2014Contrat 119566, juin 1967.Howard, county of Argenteuil.Area 14,928 square feet.Municipal taxes and costs: $67.79; school taxes and costs: $106.66.Total: $174.45.Brigitte Ruth (Godin) Wolpert, Waldker-cherstrasse 8, Freiburg, Brusgau, Germany.\u2014 Deed 117000, November, 1966.Lot 4, subdivision 5, range V, lot 5, subdivision 54, range V on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Area 11,385 sq.ft.Municipal taxes and costs: $10.93; school taxes and costs: $3.20.Total: $14.13.Domaine Howard Ltée, (bankruptcy, file 815), L.Claude Mercure, trustee, 804 Stock Exchange Tower, Montreal, Québec\u2014Deed 122339, January, 1968.Lots 1-A subdivision 11-1 to 11-13, range VI and 2-A, subdivision 11, range VI on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Bounded on the northeast by Saint-Joseph Lake, on the south-cast by a part of an unsubdivided part of original lot 1-A, southwest by an unsubdivided part of lots 1-A-ll and 2-A, northwest by lot 2-A-10.Area 82,641 square feet.Municipal taxes and costs : $3,305.87 ; school taxes and costs : $7,682.37.Total: $10,988.24.Lucien Chastenais, 9870,63rd Avenue, Rivièrc-des-Prairies.\u2014Deed 107777, October, 1964.Lot 7, subdivisions 112, 113, 114, 115, range VI on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Area 10,000 square feet.Municipal taxes and costs: $12.40; school taxes and costs: $16.58.Total: $28.98.Jean Gagnon, 9670, 70th Avenue, Rivière-des-Prairies.\u2014Deed 104183, December, 1963.Lot 7, subdivisions 339 to 342, range VI and lot 8, subdivisions 376, range VI on the official plan and book of reference of .the township of Howard, county of Argenteuil.Area 10,000 square feet.Municipal taxes and costs: $12.40; school taxes and costs: $13.07.Total: $25.47.Pierrette Benoit, 10770 Vinnney, Montreal, Québec\u2014Deed 104371, January, 1964.Lot 7, subdivisions 369, 370 and 371, range VI on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Area 7,500 square feet.Municipal taxes and costs: $9.69; school taxes and costs: $5.71.Total: $15.40.Daniel Bertonc, 3135 Langelier Blvd., Montreal, Québec\u2014Deed 118366, March, 1967.Lot 7, subdivisions 389, 390 and 391 range VI on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Area 7,500.Municipal taxes ond costs: $9.84; school taxes and costs: $5.71.Total: $15.55.Edouard Labbé, 5200, 3rd Avenue, Apt.4, Montreal.\u2014Lot 7, subdivisions 693, 694, 695 and 696, range VI on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Area 10,000 square feet.Municipal taxes and costs: $15.36; school taxes and costs: $16.58.Total: $31.94.Maurice Bordelcau, 4705 Hochelaga, upt.3.Montreal.\u2014 Deed 98790, July, 1962.Lot 7, subdivision 908, range VI on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argcnteuil.Area 13,400 square feet.Municipal taxes and costs: $16.49; school taxes and costs: $27.94.Total: $44.43.Paul Dionnc cedes to Jacques Lefebvre, 11785 Poutrincourt, Montreal\u2014Deed 119566, June, 1967. 1952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, «\u2022 18 Premier emplacement: lot 8, subdivilons 188, 189 et 190, rang VI, superficie 7,500 pieds carrés lot 8 partie ouest, subdivision 191, rang VI, superficie 1,500 pieds carrés lot 8 partie est, subdivision 187, rang VI, superficie 1,000.Deuxième emplacement: lot 8, subdivisions 229 ct 230, rang VI, superficie 2,500, lot 8, partie nord, subdivision 198, superficie 4,000 lot 8 partie est, subdivision 228, superficie 1,000 pieds carrés.Total 10,000 pieds carrés aux plan et livre de renvoi officiel du canton d'Howard, comté d'Argenteuil.Taxes municipales et frais: $17.92; taxes scolaires et frais: $35.05.Total: $52.97.Faillite Capitol Const.Inc.a Stephen H.Miller (Trustee) représenté par Marlenc Zacharin, adresse inconnue.\u2014 Contrat 113547, février 1966.Lot 8, subdivisions 235, 236, 237 ct 238, rang VI, aux plan ct livre de rnvoi officiel du canton d'Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 10,000 pieds carrés.Taxes municipales et frais: $18.07; taxes scolaires ct frais: $13.07.Total: $31.14.Maurice Durand, 4344 Saint-Zotiquc, Montréal, Québec\u2014 Contrat 109816, mai 1965.Lot 8, subdivisions 330, 331, 332 et 333, rang VI aux plan ct livre de renvoi officiel du canton d'Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 10,000 Taxes municipales et frais: $16.08; taxes scolaires et frais: $16.58.Total: $32.66.Émilien Hamcl, 1977 Lebrun, Jacques-Cartier\u2014Contrat 119227, juin 1967.Lot 8, subdivisions 441, 442, 443 ct 444, rang VI aux plan et livre de renvoi officiels du canton d'Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 10,000 pieds carrés.Taxes scolaires et frais: $7.61.Michel Archambault, 6549, 24e Avenue, Rose-mont, Montréal.\u2014Contrat 109264, mars 1965.Lot 8, subdivisions 465, 466, 467 ct 468, rang VI aux plan ct livre de renvoi officiels du canton d'Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 10,000 pieds carrés.Taxes municipales ct frais: $15.25; taxes scolaires ct frais: $19.84.Total: $35.09.Jean Forest, 5918 Est, Boul.Gouin, Montréal.\u2014 Contrat 104646, février 1964.Lot 8, subdivision 906, rang VI aux plan ct livre de renvoi officiel du- canton d'Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 10,000 pieds carrés.Taxes municipales et frais: $14.46; taxes scolaires et frais: $16.35.Total: $30.81.Wilfrid Levcrt, 2519 Lafontainc, Montréal.\u2014 Contrat 105547, mai 1964.Lot 8, subdivisions 879 ct 880, rang VI aux plan et livre de renvoi officiel du canton d'Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 9,300 pieds carrés.Taxes municipales et frais: $16.98; taxes scolaires ct frais: $8.75.Total: $25.73.Bernard Lefebvre, 3015 Bedford, apt.14, Montréal.\u2014 Lot 8, subdivision 917, rang VI aux plan et livre de renvoi officiel du canton d'Howard comté d'Argenteuil.Superficie 10,000 piedscarrés.Taxes scolaires ct frais: $16.35.Roland Bergevin, 969 Sainte-Marguerite, Saint-Henri, Montréal \u2014Contrat 114598, mai 1966.Lot 8, subdivision 953, rang VI au plan et livre de renvoi officiel du canton d'Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 11,250 pieds carres.Lot 8, subdivision 954, rang VI au plan et livre de renvoi officiel du canton d'Howard, comté First emplacement: lot 8, subdivisions 188, 189 and 190, range VI, area 7,500 square feet! lot 8 west part, subdivison 191, range VI, area 1,500 square feet, lot 8 cast part, subdivision 187, range VI, area 1,000.Second emplacement: lot 8, subdivisions 229 and 230, range VI, area 2,500, lot 8, north part, subdivision 198, area 4,000 lot 8 east part, subdivision 228, area 1,000 square feet.Total 10,000 square feet on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Municipal taxes and costs: $17.92; school taxes and costs: $35.05.Total: $52.97.Bankruptcy Capitol Const.Inc., to Stephen H.Miller (trustee) represented by Marlene Zacharin address unknown.\u2014 Deed 113547, Februarv, 1966.Lot 8, subdivisions 235, 236, 237 and 238, range VI, on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Area 10,000 square feet.Municipal taxes and costs: $18.07; school taxes and costs: $13.07.Total: $31.14.Maurice Durand 4344 Saint-Zotiquc, Montreal, Québec\u2014Deed 109816, May, 1965.Lot 8, subdivisions 330, 331, 332 and 333, range VI on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Area 10,000.Municipal taxes and costs: S 16.08; school taxes and costs: $16.58.Total: $32.(16.Émilien Hamel, 1977 Lebrun, Jacques-Cartier\u2014Deed 119227, June, 1967.Lot 8, subdivisions 441, 442, 443 and 444, range VI on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argcnteuil.Area 10,000 square feet.School taxes and costs: $7.61.Michel Archambault, 6549,24th Avenue, Uose-mont, Montreal\u2014Deed 109264, March 1965.Lot 8, subdivisions 465, 466, 467 ami 46S, range VI on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Area 10,000 square feet.Municipal taxes nnd costs: $15.25; school taxes and costs: $19.84.Total: $35.09.Jean Forest, 5918 Gouin Blvd.East, Montreal\u2014 Deed 104646, February 1964.Lot 8, subdivision 906, range VI on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Area 10.000 square feet.Municipal taxes and costs: $14.46; school taxes and costs: $16.35.Total: $30.81.Wilfrid Invert, 2519 Lafontainc, Montreal.\u2014 Deed 105547, May, 1964.Lot 8, subdivisions 879 and 880, range \\ I on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argcnteuil.Area 9,300 square feet.Municipal taxes and costs: $16.98; school taxes and costs: $8.75.Total: $25.73.Bernard lefebvre, 3015 Bedford, Apt.14, Montreal \u2014 Lot 8, subdivision 917, ronge \\ I on the official plan and hook of reference ol the township of Howard, county of Argcnteuil.Area 10,000 square feet.School taxes and costs: $16.35.Roland Bergevin, 969 Ste.Marguerite, St.Henri, Montreal.\u2014Deed 114598, May, 1966.Lot 8, subdivision 953, range VI on the official plan and book of reference of the township of Howard, county of Argenteuil.Area 11,250 square feet.Lot 8, subdivision 954, range VI on the official plan and book of reference of the township ol QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 1953 d'Argenteuil.Superficie 10,175 pieds carrés.Contrat 118354, mars 1967.Taxes scolaires et frais: $54.31.Douât Gilbert, 5165 Jeanne-Mance, Montréal, Québec.\u2014 Contrat 112489, novembre 1965.Lot 9, subdivision 25, rang VI aux plan ct livre de renvoi officiel du canton d'Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 8, 250 pieds carrés.Taxes municipales et frais: $14.20; taxes scolaires et frais: $7.64.Total: $21.84.(ïérard Paquette, 9131, 24c Avenue, Saint-Micliel, Montréal \u2014 Contrat 120125, août 1967.Lot 9, subdivision 35, rang VI aux plan et livre de renvoi officiel du canton d'Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 7,275 pieds carrés.Taxes municipales ct frais: $12.92; taxes scolaires et frais: $11.42.Total: $24.34.André Fortin, 8159, 10e Avenue, Saint-Michel, Montréal.\u2014Contrat 112623, novembre 1965.Lot 9, subdivision 115, rang VI aux plan et livre de renvoi officiel du canton d'Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 8,062.5 pieds carrés.Taxes municipales et frais: $23.62; taxe scolaire: $22.04.Total: $45.66.Guy Vallières, adresse inconnue.\u2014 Contrat 11977*4, juillet 1967.Loi 5-A, subdivision 12, rang VI aux plan ct livre 3S45-«> 4778-53 Dulac inc.\"Dulac inc.\", gives notice that it lias changed its head office from number 9 St-Cyrille Street, Sainte-Maric, county of Bcaucc, to number 750 Trans-Canada Highway, Lauzon.Paul-R.Tiiiviehge, Secretary.33S45 4778-53 KudcxInc.Avis est, par la présente, donné que « Kadex Inc.», constituée en corporation en vertu de lu premiere partie de la Loi des compagnies, par icttres patentes en date du 14 avril 1958, a transporté son siège social de suite 435, 4950 Queen Mary Road, Montréal, Québec, à suite 514, 4 Place Ville Marie, Montréal, Québec.Montréal, Québec, ce 12c jour de mars 1970.Le secrétaire-trésorier, Céline Trudeau.33847-0 11239-58 Kadex Inc.Notice is hereby given that \"Kadex Inc.\", incorporated under Pnrt I of thc Companies Act by letters patent dated on April 14, 1958, has moved its head office from 4950 Queen Mary Road, suite 435, Montreal, Québec, to suite 514, 4 Place Ville Marie, Montreal, Québec.Montreal, Québec, this 12th day of March 1970.Céline Trudeau, Secretari/-Trcasurer.33847 11239-58 Ludex Inc.Avis est, par la présente, donné que « Ludcx Inc.», constituée en corporation vertu de la premiere partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 14 avril 1958, a transporté son siège social de suite 435, 4950 Queen Mary Road, Montréal, Québec, à suite 514, 4 Place Ville Marie, Montréal, Québec.Montréal, Quél>cc, ce 12e jour de mars, 1970.La secrétaire-trésorière, Céline Trudeau.33S49-0 11238-5S Ludcx Inc.Notice is hereby given that \"Ludex Inc.\", Incorporated under Part I of thc Quél>cc Companies Act by letters putent dated April 14, 195S, has moved its head office from 4950 Queen Mary Road, suite 435, Montreal, Québec, to suite 514, 4 Place Ville Marie, Montreal, Québec.Montreal, Québec, this 12th day of March, 1970.Céline Trudeau, Secretary-Treasurer.33S49-0 11238-58 1986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n\" 13 Labelle ventilation inc.La compagnie « Labelle ventilation inc.», donne avis qu'elle a changé son siège social de Montréal, au numéro 4025, boulevard Lite, Laval, Quartier St-Vincent-dc-Paul.Le secrétaire, Richard Skeene.33848-0 13748-62 Labelle ventilation inc.\"Labelle ventilation inc.\", gives notice that it has changed its head office from Montreal to number 4025 Lite Blvd., Laval, St-Vinccnt-de-Paul Ward.Richard Skeene, Secretary.33848 13748-62 Pcnnzoil de Québec limitée Avis est par les présentes donné que « Pcnnzoil de Québec limitée», une corporation constituée par lettres patentes accordées en vertu de la Loi des compagnies lc 4e jour d'août 1964, ct ayant son siège social à Québec, où jusqu'à ce jour, son bureau était situé à bureau 42, 81, rue St-Pierre, Québec, l'a transporté à 55, D'autcuil, Québec, Québec.À compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Houston, Texas, ce 8c jour d'octobre 1969.Le procureur de la compagnie, Me Michael Sheehan.33850 3506-64 Pcnnzoil de Québec limitée Notice is hereby given that \"Pennzoil de Québec limitée\", incorporated by letters patent granted pursuant to the Companies Act on thc 4th day of August, 1964, and having its head ollicc in Québec, where its office was situated up to today, at Room 42, 81 St-Pierre Street, Québec, has moved it to 55 D'autcuil, Québec, Québec.From and after the date of this notice and the said office shall be considered by thc compuny as being the head office of the company.Dated at Houston, Texas, this 8th day of October, 1969.Me Michael Sheehan, Attorney for the Company.33850-o 3506-64 Kodex Inc.Avis est, par la présente, donné que « Rodcx Inc.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes en date du 14 avril 1958, a transporté son siège social de suite 435, 4950 Queen Mary Road, Montréal, Québec, à suite 514, 4 Place Ville Marie, Montréal, Québec.Montréal, Québec, ce 12e jour de mars, 1970.33851-0 IjO secrétaire-trésorière, Celine Trudeau.11240-58 Kodcx Inc.Notice is hereby given that \"Rodcx Inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated April 14,1958,'has moved its head office from 4950 Queen Mary Road, suite 435, Montreal, Québec, to suite 514, 4 Place Ville Marie, Montreal, Québec.Montreal, Québec, this 12th day of March, 1970.Celine Trudeau, Secretary-Treasurer.33851-0 11240-58 Vildex Inc.Avis est, par la présente, donne que «Vildex Inc.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes en date du 3 février 1958, a transporté son siège social de suite 435, 4950, Queen Mary Road, Montréal, Québec, à suite 514, 4, Place Ville Marie, Montréal, Québec.Montréal, Québec, ce 12c jour de mars 1970.33852-0 La secrétaire-trésorière, Céline Trudeau.10390-58 Vildex Inc.Notice is hereby given tliat \"Vildex Inc.\", incorporated under Part I of thc Companies Act by letters patent dated February 3, 1958, has moved its head office from 4950 Queen Mary Road, suite 435, Montreal, Québec, to suite 514, 4 Place Ville Marie, Montreal, Québec.Montréal, Québec, tliis 12th day of March, 1970.Céline Trudeau, Secretary-Treasurer.33852-0 10390-58 Avis divers Miscellaneous Notices Succession Georges Allard Prenez avis que Dame Céline Bert rand-Allard, ménagère, domiciliée à Saint-Adolphe-d'Howard, dans le comté d'Argenteuil, a accepté purement et simplement la succession de feu Georges Allard, décédé le 21 octobre 1969, aux termes d'un acte passé devant Me Ghyslain Lapointe, notaire à Sainte-Agathe-des-Monts, le 5 mars 1970 et enregistré au bureau d'enregistrement d'Argenteuil sous le numéro 132,957.Le procureur de la requérante, 33860-o Ghyslain Lapointe, notaire.Estate of Georges Allard Take notice that Mrs.Céline Bertrand-A Hard, housewife, domiciled at Saint-Adolphe-d'Howard, in the county of Argcnteuil, accepted purely and simply thc estate of the late Georges Allard, deceased the 21st day of October, 1969, according to the terms of a deed passed before Me Ghyslain Lapointe, notary, at Sainte-Agathe-des-Mnnts, on March 5, 1970 and registered at thc registry office of Argenteuil under number 132,957.Ghyslain Lapointe, Notary, 33860 Attorney for the petitioner. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 1987 Le Conseil Hérouxville No 6053 des Chevaliers de Colomb de Hérouxville inc.Le « Conseil Hérouxville No 6053 des Chevaliers de Colomb de Hérouxville Inc.», Hérouxville, comté de Laviolette, donne avis, par les présentes, qu'il possède son siège social à l'adresse susmentionnée et qu'il se prévaut des dispositions de la Loi concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec (1-2 Elizabeth II, chap.134) à partir du 5 février 1970.St-Tiraothée, 5 février 1970.Le grand chevalier, Augustin Tremblay.Le secrétaire-archiviste, 33786-0 Charles Bordeleau.Successions Thérèse et Jean Belleau Avis est donné que Monsieur Paul E.Belleau, es qualité de curateur à la personne et aux biens de Mlle Germaine Belleau, suivant jugement de la Cour Supérieure en date du 29 décembre 1969, a accepté sous bénéfice d'inventaire, par acte passé devant le notaire soussigné, le 10 mars 1970, la succession de Thérèse Belleau, en son vivant rentière, domiciliée à Québec, à l'Hôpital Général de Québec, décédée a cet endroit le 9 décembre 1969 et le 11 mars 1970, la succession de Mgr Jean Belleau, en son vivant prêtre, domicilié à Québec et décédé à Courvillc le 14 octobre 1969.Les deux acceptations sous bénéfice d'inventaire ont été enregistrés à Québec, le 12 mars 1970, sous les numéros 664669 et 664670.Québec, ce dix-huitième jour du mois de mars mil neuf cent soixante-dix.Le notaire, 33817-0 H.-Paul Martin.The Council Hérouxville No.6053 of thc Knights of Hérouxville Inc.The \"Council Hérouxville No.6053 of the Knights of Columbus of Hérouxville Inc.\", Hérouxville, County of Laviolette, hereby gives notice that its head office is located at the above mentioned address and that it is availing itself of the provisions of the Act respecting the Knights of Columbus of the province of Québec (1-2 Elizabeth II, chap.134, sec.2a) as from February 5, 1970.St-Timothéc, February 5, 1970.Augustin Tremblay, Grand Knight.Charles Bordeleau, 33786-o Recorder.Estates of Thérèse and Jean Belleau Notice is hereby given that Paul E.Belleau, curator to the person and property to Germaine Belleau, by judgment of the Superior Court on December 29, 1969, have accepted under benefit of inventory, by a declaration signed before the undersigned notary on March 10, 1970, in respect of thc estate of Thérèse Belleau, in her life-time domiciled at Québec, at the General Hospital of Québec and deceased at the same place on December 9, 1969 and on March 11, 1970, the estate of Mgr Jean Belleau, in his lifetime priest, domiciled at Québec and deceased at Courville on October 14, 1969.The two acceptances under benefit of inventory have been registered at Québec, on March 12, 1970, under numbers 664669 et 664670.Signed at Québec, this eighteenth day of March on thc year one hundred and seventy.H.-Paul Martin, 33817-o Notary.Caisses d'épargne et de crédit La Caisse Populaire Desjardins de Terre des Hommes (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que lc ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives, a approuvé le règlement adopté le 25e jour de février 1970 par < La Caisse populaire Desjardins de l'Expo « 1967 », changeant son nom en celui de « La Caisse Populaire Desjardins de Terre des Hommes ».Québec, le 18 mars 1970.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 33861-0 Ls-Philippe Bouchard.Savings and Credit Unions La Caisse Populaire Desjardins de Terre des Hommes (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that thc Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved thc regulation adopted on the 25th day of February, 1970 by \"La Caisse populaire Desjardins de l'Expo \"1967\", changing its name into that of \"La Caisse Populaire Desjardins de Terre des Hommes\".Québec, March 18, 1970.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 33861 Companies and Cooperatives.Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Jack Cohen Avis est par les présentes donné que Jack Cohen présentement domicilié à 4300 rue Bou-chette Montréal, province de Québec, présentera une demande au ministre de la justice de la province de Québec, pour l'adoption d'un décret changeant son nom à James Jack Star.Duté à Montréal, 19 mars, 1970.Les procureurs du requérant, 33818-13-2-0 Louis & Berger.Change of name Act Applications Jack Cohen Notice is hereby given that Jack Cohen, residing at 4300 Bouchette Street, Montreal, Québec, Manager, shall apply to the Minister of Justice for an order changing his name to James Jack Star.Dated at Montreal, March 19, 1970.Louis & Berger, 33818-13-2-0 Attorneys for applicant. 19S8 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 18 Vahan Hatcher Vartazarmian Avis est donné que Valian Hatcher Vartazarmian, résidant à 5375, Walkley Avenue app.208 Montréal 265, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir le changement de son nom en celui de Vahan Vartian.Ledit changement de nom devra aussi concerner ma femme ct ma fille mineure dont les noms seront changes en Éliane Vartian et Michèle Vartian.Montréal, le 9 février 1970.Vahan Hatcher Vartazarmian.33651-12-2-0 Vahan Hatcher Vartazarmian Notice is given that Vahan Hatcher Vartazarmian, residing at 5375 Walkley Avenue, Apt.208, Montreal 265, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to change his name into that of Vahan Vartian.The said change of name must also concern my wife and my minor daughter, the names of whom shall be changed into Elianc Vartian and Michèle Vartian.Montreal, February 9, 1970.Vahan Hatcher Vartazarmian.33651-12-2 Hristos llristou Avis est donné, pur les présentes, que Hristos Hristou, surveillant d'entrepôt, du 779 avenue Godin, dans la cité de Verdun, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom pour celui de Christie Christophe.Avis est de plus donné que ce décret profitera à son épouse, Dimitra Spiro Christophe, qu'il profitera aussi, dans la mesure nécessaire, à son fils, Steven Stcfanos Christophe, ainsi qu'à sa fille, Christina Bargain Christophe, résidant tous à l'adresse ci-haut mentionnée.Daté à Montréal, ce 10c jour de mars 1970.Les procureurs du requérant, Buchanan, McAllister, 33687-12-2-o Blakely & Ham.Hristos llristou Notice is hereby given that Hristos llristou, warehouse attendant, of 779 Godin Avenue in thc city of Verdun, will apply to thc Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing his name to that of Christie Christophe.Notice is further given that this order shall benefit his wife, Dimitra Spiro Christophe, and that it will further benefit, to thc extent necessary, his son, Steven Stcfanos Christophe, and his daughter, Christina Barbara Christophe, all living at the above mentioned address.Dated at Montreal, this 10th day of March, 1970.Buchanan, McAllister, Blakely & Ham, 33687-12-2-0 Attorneys for Petitioner.Barry Howard Tcitelbaum Avis est par les présentes donné que M.Barry Howard Tcitelbaum demeurant au 1430, rue Saint-Marc, ville ct district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil un décret changeant son nom en celui de Barry Howard Hart.Le procureur du requérant, 33688-12-2 Seymour Machlovitch.Barry Howard Tcitelbaum Notice is hereby given that Mr.Barry Howard Tcitelbaum residing at 1430 St.Marc Street, city and district of Montreal, will apply to the Lieutenant Governor in council in order that his name be changed to that of Barry Howard Hart.Seymour Machlovitch, 336S8-12-2-o Attorney for A ppUcunt.Bert Tcitelbaum Avis est par les présentes donné que Bert Tcitelbaum demandera au ministre de la Justice de la province de Québec de changer son nom de Tcitelbaum en celui de Hart.Le nom de Mme Mina Tcitelbaum ct de leurs enfants mineurs, Michael Brian, Robert Bradley et Corey Mitchell, qui tous habitent avec le requérant au 101 Brittany, à Ville Mont-Royal, district de Montréal, sera aussi changé par la présente requête.Le procureur de la requérante, 33689-12-2 Seymour Machlovitch.Bert Tcitelbaum Notice is hereby given that Bert Tcitelbaum will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec for a change of his surname from Tcitelbaum to Hart.The name of Mrs.Mina Tcitelbaum, and their minor children, Michael Brian, Robert Bradley, and Corey Mitchell, all of whom reside with thc applicant at 101 Brittany in the town of Mount-Royal, district of Montreal, will also be changed by thc present application.Seymour Machlovitch, 33689-12-2-0 Attorney for Applicant.Michael Tcitelbaum Avis est par les présentes donné que Michael Tcitelbaum demandera au ministre de la Justice de la province de Québec de changer son nom de Teitelbaum en celui de Hart.Le nom de Mme Katherine Teitelbaum ct de ses enfants mineurs, David John, Caroline Robin, Jordana Ann, qui tous demeurent avec le requérant à 187, Glengarry, à Ville Mont-Royal, district de Montréal, sera aussi changé pnr la présente requête.Le procureur du requérant, 33690-12-2 Seymour Machlovitch.Michael Tcitelbaum Notice is hereby given that Michael Teitelbaum will apply to the Minister of Justice of thc Province of Québec for a change of his surname from Teitelbaum to Hart.Thc name of Mrs.Katherine Teitelbaum, nnd their minor children, David John, Cnroline Robin, Jordana Ann all of whom reside with the applicant at 187 Glengarry in the town of Mount-Royal, district of Montreal, will also be changed by the present application.Seymour Machlovitch, 33690-12-2-o Attorney for Applicant. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.IS 1989 Joseph Ernest Dion (dit Soulière) Avis est donné que Joseph Ernest Dion (dit Soulière), journalier, domicilié et résidant au numéro 45 de la rue Davis, dans les cité et district de Hull, province de Québec, s'adressera au ministre de la justice de la province de Québec pour faire changer son nom de Joseph Ernest Dion à Joseph Ernest Soulière.Hull, le 3 mars, 1970.Les procureurs du requérant.Boulanger, Bergeron 33819-13-2-0 & Belec Joseph Ernest Dion (dit Soulière) Notice is given that Joseph Ernest Dion (dit Soulière) residing at 45 Davis Street, Hull, District of Hull, Province of Québec, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec, for an order changing his name to Joseph Ernest Soulière.Hull, March 3rd, 1970.Boulanger, Bergeron & Belec, 33819-13-2-0 Solicitors for the Petitioner.Jumes Arthur Parks Avis est donné que M.James Arthur Parks, ouvrier métallurgiste, domicilié et résidant nu 2390 do la rue Oran, à Duvcrnay, Laval, province de Québec, demandera un décret au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec pour changer son nom pour Arthur Wallace .Maxwell, suivant le S.R.Q.1965, chapitre 77, son épouse, Madame Joyce Anna Lucie Stcin donnant son consentement.Montréal, ce 27 février 1970.Robert, Proulx 33787-13-2-0 & Dansereau.Juiin¦- Arthur l'arks Notice is given that Mr.James Arthur Parks, core-maker, residing and domiciled at 2390 Oran Street, Duvcrnay, Laval, Province of Québec, will request an order in council from the Lieutenant-Governor in council of the Province of Québec to change his name to Arthur Wallace Maxwell, according to 1965, R.S.Q., chapter 77, his consort, Mrs.Joyce Anna Lucie Stein consenting.Montreal, February 27, 1970.Robert, Proulx 33787-13-2-0 & Dansereau.Szaholcs Halmagyi Avis est donné que Szaholcs Halmagyi dc 5501 Adalbert Montréal, a l'intention de présenter au Lieutenant-gouverneur en conseil une requête pour lc changement dc son nom à Samuel Hart, tel que prévu par les dispositions de la Loi du changement de nom.Montréal, le 6 mars 1970.Les procureurs du requérant, 33820-I3-2-o Bohémikr & Ciiénard.Szaholcs Halmagyi Notice is given that Szaholcs Halmagyi, of 5501 Adalbert, Montreal, intends to present a petition to thc Lieutenant-Governor in Council requesting thc change of his name to Samuel Hart, pursuant to thc provisions of the Change of Name Act.Montreal, March 6, 1970.Boiiémier & Ciiénard, 33820-13-2-o Attorneys for the petitioner.Leslie Mariahegyi Avis est par les présentes donné que Leslie Marinhegyi technicien, domicilié et résidant au 11.490 boulevard Gouin O.Apt.301, dans les ville cl district de Picrrefonds, Que., s'adressera au ministre dc la Justice pour obtenir la permission de changer son nom en celui de Leslie Hegyi, changement qui s'applique aussi à son épouse, née Madeleine Helic, domiciliée uu même endroit.Le procureur du requérant, 33821-13-2-0 Jacques-E.Fortin.I.r-lir Mariahegyi Notice is hereby given that Leslie Mariahegyi, technician domiciled and residing at 11,490 Blvd.Gouin W.Apt.301, in the city and district of Picrrefonds, Que., will apply to the Minister of Justice to change his name to Leslie Hegyi and to benefit his wife, née Madeleine Helic, domiciled at the same place.Jacques-E.Fortin, 33821-13-2-0 Attorney for petitioner.Roger Putin (alia- Pctiu) Avis est par les présentes donné que Roger Putin, alios Petin, employé de restaurant, résidant et domicilié au 3221 Edouard Montpetit, Apt.18, en les cité et district de Montréal, province de Québec, transmettra au ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives, une requête demandant que son nom soit changé de Roger Putin à Roger Petin ct que ce changement bénéficie à son épouse, Dame Monique Laflannne Putin ct ù leur fille Dominique Clémentine Putin.Montréal, le 16 mars 1970.Les procureurs du requérant, Desciiènes, de Grandpré, Colas, 33822-13-2-0 Godin & Lapointe.Roger Putin (alias Petin) Notice is hereby given that Roger Putin, alias Petin, restaurant employee, residing and domiciled at 3221 Edouard Montpetit, Apt.18, in the city and district of Montreal, Province of Quebec will transmit to the Minister of Financial Institutions Companies and Cooperatives, an application to modify his name from Roger Putin to Roger Petin, and that thc said modification shall benefit his wife, Monique Laflammc Putin and their daughter Dominique Clementine Putin.Montreal, March 16, 1970.Desciiènes, de Grandpré, Colas, Godin & Lapointe, 33822-13-2-0 Attorneys for petitioner. 1990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 13 Martina Reimcr Avis est par les présentes donné que Dame Doris Martha Maria Ottc Reimcr Koester, tutrice de l'enfant mineur, Martina Reimer, résidant au 3877 Moore, Fabrcville, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant dc changer le nom dc son enfant mineur dc Martina Reimer à Martina Reimer Koester.Montréal, le 24 février 1970.33823-13-2-0 Me Simon Richteh.Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Ernest Wilfrid Chadler Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1079, du 11 mars 1970, d'effectuer le changement dc nom de Ernest Wilfred Chornomydz en celui de Ernest Wilfred Chadler.Québec, le 17 mars 1970.Le sous-minislre associé de la justice, 33824-o Lucien Darveau, c.r.David Gallcr Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1076, du 11 mars 1970, d'effectuer lc changement de nom «le Stanislaw Cieslinski en celui de David Caller.Québec, le 17 mars 1970.Le sous-minislre associé de la justice, 33824-0 Lucien Darveau, ch.Giuseppe Lazzaronc Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1077, du 11 mars 1970, «l'effectuer lc changement dc nom «le Tino Foster en celui de Giuseppe Lazzaronc.Québec, le 17 mars 1970.Le sous-minislre associé de la justice, 33824-o Lucien Dahveau, ch.Arnold Aaron Tincro Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1078, du 11 mars 1970, d'effectuer lc changement de nom de Arnold Aaron Titinero en celui de Arnold Aaron Tincro.Québec, le 17 mars 1970.Le sous-ministre associé de la justice, 33824-0 Lucien Darveau, ch.Compagnie autorisée à faire des affaires Tingue, Brown & Co.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Tingue, Brown & Co.» a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Emile Marion, 2518, avenue Haig, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 2518, avenue Haig, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33785 c-5-88 Martina Reimer Notice is hereby given that Dame Doris Martha Maria Ottc Reimer Koester, tutrix to thc minor child Martina Reimcr, residing at 3877 Moore, in Fabreville, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing her minor child's name from Martina Reimer to tliat of Martina Reimer Koester.Montreal, February 24, 1970.33823-13-2-0 Me Simon Riciiteh.Change of name Act Granted Ernest Wilfrid Chadler The Lieutenant-Governor in Council bus Innm pleased, by decree Number 1079 of March 11, 1970, to effect thc change of name of Ernest Wilfred Chornomydz into that of Ernest Wilfred Chadler.Québec, March 17, 1970.Lucien Darveau, q.c., 33824 Associate Deputy Minister of Justice.David Gallcr The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree Number 1076 of March 11, 1970, to effect thc change of name of Stanislaw Cieslinski into tliat of David Gallcr.Québec, March 17, 1970.Lucien Dahveau, q.c.33824 Associate Depuly Minister of Justice.Giuseppe Lazzarone The Lieutenant-Governor in Council has lieen pleased, by decree Number 1077 of March 11, 1970, to effect the change of name of Tino Foster into that of Giuseppe Lazzarone.Québec, March 17, 1970.Lucien Darveau, q.c, 33824 Associate Deputy Minister of Justice.Arnold Aaron Tinero The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 1078 of March 11, 1970, to effect the change of name of Arnold Aaron Titinero into tliat of Arnold Aaron Tinero.Québec, March 17, 1970.Lucien Darveau, q.c, 33824 Associate Deputy Minister of Justice.Company Licensed to do Business Tingue, Brown & Co.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act \"Tingue, Brown & Co.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against thc company is Mr.Emile Marion, 2518 Haig Avenue, Montreal.The principal office of the company in t'ie Province is at 2518 Haig Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalircs.33785-o e-5-88 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.IS 1991 Demandes à la Législature Cité dc Lachute Avis public est par les présentes donné que la « Cité de Lachute », dans le comté d'Argenteuil s'adressera à l'Assemblée Nationale de la Province de Québec, à sa présente ou prochaine Session, pour l'adoption d'une loi modifiant ses limites territoriales, et annexant à cette fin le territoire de lu municipalité de la paroisse dc St-Jérusalem d'Argenteuil, une partie du territoire de la municipalité de St-André d'Argenteuil et une partie du territoire des municipalités du Canton de (ïorc ct du Canton de Chatham, le tout tel qu'il appert à un plan ct à une description technique préparés par monsieur J.Arthur Lafrance, arpenteur-géomètre, datés du vingt-cinq novembre 1909 ct portant le numéro 839, cedit plan ct cette description technique sont déposés à l'Hôtel de Ville dc la cité de Lachute où il peut en être pris connaissance par tous les intéressés.Donné à Lachute, ce 14 février 1970.Le secrétaire-trésorier de la cité de Lachute, 33545-IO-4-o Ronald Hébert.Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée la Fabrique dc la Paroisse Stc-Madcleinc Avis est par les présentes donné que « Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée et La Fabrique île la paroisse Ste-Madeleine », toutes deux corporations légalement constituées, s'adresseront à la Législature dc la province de Québec, à sa présente session, pour demander l'adoption d'une loi spéciale pour les fins suivantes: 1° Abroger la loi 3, Edouard VII, Chapitre 109 (1903): 2° Approuver, confirmer et ratifier certaines conventions et transactions faites entre les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée et la Fabrique dc la paroisse Stc-Madcleinc, suivant acte reçu devant Me Jérôme Loranger, notaire, lc 23 février 1970, sous le numéro 14395 de ses .Minutes; 3° Confirmer et ratifier les titres respectifs de la Fabrique de la paroisse Ste-Madclcine et dc Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée ù certains immeubles.Twis-Rivières, le 24 février 1970.Le* procureurs des pétitionnaires, Lajoie, Lajoie, Gouin, Vioeant 33540-IO-4-o & Desaulniers.Les Sueurs dc la Charité dc Saint-Ix>uis (Pro\\ inec dc Notre-Dame de l'Annonciation) Avis est par les présentes, donné que « Les Soeurs de lu Charité dc Suint-Louis (Province de Notre-Dame de l'Annonciation) », s'adresseront à l'Assemblée nationale du Québec à sa présente session pour obtenir la passation d'une loi leur permettant de créer une nouvelle corporation avec les pouvoirs habituels des corporations religieuses, particulièrement le droit d'incorporer des maisons, pour valider certains actes et certains titres de propriété, et pour tous autres pouvoirs, et pour transporter certains biens à la nouvelle corporation.Montréal, le 25 février 1970.Les procureurs de la requérante.Monette, Filion, Clerk, Miciiaud, 33547-10-4-o Barakett et Levesque.Applications to Legislature City of Lachute Public notice is hereby given that thc \"City of Lachute\", in the county of Argenteuil will apply to thc National Assembly of thc Province of Québec, at its present or next Session, for the adoption of an act modifying its present territorial limits by annexing the territory of the municipality of the parish of St-Jcrusalem of Argenteuil, part of the territory of the municipality of St-André d'Argenteuil, and part of the territory of the municipalities of the townships of Gore and Chatham, the whole as shown in a plan and technical description prepared per Mr J.Arthur Lafrance, Land Surveyor, dated on November thc 25th 1969, and bearing No 839, said plan and technical description are deposited at the Town Hall of the city of Lachute, for the information of all interested persons.Given in Lachute, this February 14, 1970.Ronald Hébert, Secretary- Treasurer 33545-10-4-0 of the city of I/xchule.les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée La Fabrique de la Paroisse Ste-Madeleine Notice is hereby given that \"Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée and La Fabrique de la paroisse Ste-Madeleine\", both duly incorporated corporations, will apply to the Legislature of the province of Québec at its present Session, for the adoption of a special Act for thc following purposes: 1.To repeal an Act being Chapter 109, 3, Edouard VII (1903) 2.To approve, confirm and ratify certain agreements and transactions made between Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée and La Fabrique dc la paroisse Ste-Madclcine as per deed received before Jérôme Loranger, notary, on February 23, 1970, under No.14395 of his minutes.3° To confirm and ratify the respective titles of La Fabrique de la paroisse Ste-Madeleine and of Les Missionnaires Oblats dc Marie-Immaculée to certain immovable properties.Trois-Rivières, February 24, 1970.Lajoie, Lajoie, Gouin, Vigeant, & Desaulniers, 33546-10-4-o Attorneys for the Petitioners.Les Soeurs de la Charité dc Saint-Ix>uis (Province dc Notre-Dame de l'Annonciation) Notice is hereby given that \"Les Soeurs de la Charité de Saint-Louis (Province dc Notre-Dame de l'Annonciation) will apply to thc National Assembly of Québec at its present session for the passing of an Act allowing it to create a new corporation with the powers pertaining ordinarily to religious corporations, to give it thc right to incorporate houses, to validate certain acts and titles of property, and for any other powers, and to authorize it to transfer certain properties to the new corporation.Montreal, February 25, 1970.Monette, Filion, Clerk, Miciiaud, Barakett and Levesque, 33547-10-4-o Attorneys for Petitioner. 1992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 18 Michel Ouellct Avis est par les présentes donné que: Michel Ouellct de 42, Avenue Desnoyers-Villeneuve, app.8, Québec 5, district de Québec, s'adressera à la législature de Québec pendant sa présente session pour demander l'adoption d'une loi autorisant le Collège des Pharmaciens à l'admettre à titre d'assistant-pharmacien.Les procureurs du requérant, Du M : Mailuot 33461-10-4-o & Desaulniers.Richard Paul Avis est par les présentes donné que: Ri chu ni Paul, de 1220, Saint-Pierre, Saint-Hyacinthe, district de Saint-Hyacinthe, s'adressera à la Législature de Québec pendant sa présente session pour demander l'adoption d'une loi autorisant lc Collège des Pharmaciens à l'admettre à titre d'assistant-pharmacien.Les procureurs du requérant, Du Mesnil, Mailuot 33462-10-4-o & Desaulniers.Ville dc Laval Avis est par les présentes donné que la ville de Laval s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec ù sa procliaine session, pour l'adoption d'une loi sur les matières suivantes: Modifier l'article 525 de la Loi des cités ct villes sur la méthode de perception de la taxe prévue au paragraphe 2 dudit article, l'article 523 de la Loi des cités et villes en vue d'assujettir la maison d'habitation située sur une terre en culture au paiement des taxes générales ct spéciales, d'en établir l'évaluation ù la valeur réelle, dc définir quelle superficie d'une terre en culture ou affermée ne peut être évaluée à plus de $100 l'arpent, l'article 593 quant à l'approbation par les propriétaires des règlements décrétant des travaux d'aqueduc, d'égout, de pavage, de trottoirs, de bordures ou d'éclairage; Permettre que soit décrétée immédiatement après la fin des travaux la perception de la taxe imposée sous forme de charge fixe basée sur le front des immeubles; Modifier l'imposition prévue aux règlements en vigueur décrétant un emprunt lorsque la ville doit refaire ou remplacer les travaux qui y sont décrétés; Décréter la procédure ù suivre pour l'approbation des règlements modifiant les règlements de zonage; Fixer l'étendue en front pour fins d'imposition des lots situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires suivant les normes du règlement numéro L-1236 pour tout règlement d'emprunt adopté ayant le 26 septembre 1968; Obtenir l'autorisation de constituer un fonds résidentici pour fins de réaménagement urbain; Autoriser la vente pour des fins autres qu'industrielles ou commerciales la partie des lots connus et désignés comme étant les subdivisions un (1) et deux (2) du lot originaire numéro trois cent trente-neuf (339) du cadastre de la paroisse de St-Martin; Et sur toute autre matière qui lors de l'étude et dc la présentation du projet de loi pourrait s'avérer dans l'intérêt de la ville et de ses contribuables.Cité de Laval, ce 3e jour de mars 1970.Le procureur de la ville de Laval, 33590-12-4-o Roger Savard, c.r.Michel Ouellct Notice is hereby given tliat Michel Ouellet, of 42, Desnoyers-Villeneuve Avenue, app, 8 Québec 5, district of Québec, will apply to the Legislature of Québec, during its present session to ask for the adoption of an act, to authorize the College of Pharmacists of the Province of Québec, to admit him as assistant-pharmacist.Du Mesnil, Mailiiot & Desaulnieus, 33461-10-4-o Attorneys for the Petitioner.Richard Paul Notice is hereby given that Richard Paul, of 1220, St.Pierre, St-Hyocinthe, district of St-Hyacinthe, will apply to the Legislature of Québec, during its present session to ask for the adoption of an act, to authorize thc College of Pharmacists of the Province of Québec, to admit him as assistant-pharmacist.Du Mesnil, Mailiiot & Desaulnieiis, 33462-10-4-o Attorneys for the Petitioner.City of Laval Notice is given that the city of Laval, will apply to the National Assembly of Québec at its next session, for the adoption of an act on the following matters: Modify section 525 of the Cities and Towns Act concerning the collection of the tax mentioned in paragraph 2 of said section; section 523 of the Cities and Towns Act to render the residence located on a cultivated farm subject to general and special taxes, assess it at its real value and define which part of a farmed or cultivated land cannot be valued at more than $100 per arpent; section 593 concerning the approval by property owners of by-laws authorizing aqueduc, sewer, paving, sidewalks, curb or street lighting works; Authorize that fixed charges on the frontage of properties be levied immediately nfter the termination of public works for which they are so taxed; Modify the taxation prescribed in borrowing by-laws when the city must replace or renew the works authorized by such by-laws; Establish the procedure for the approval of by-laws modifying zoning by-laws; Fix the frontage of lots situated on street corners or lots tliat are not rectangular according to by-law L-1236 for assessment on borrowing by-laws adopted before September 26, 196S; Obtain the power to establish a residential fund for urban renewal purposes; Authorize the sale for purposes other than industrial or commercial of parts of lots known and designated as being the subdivisions 1 and 2 of original lot number 339 of the official plan and book of reference of the parish of St-Mnrtin; And for all other purposes which during the studying and presentation of the proposed Act could be in the interest of the city and its taxpayers.City of Laval, this 3rd day of March, 1970.Roger Savard, q.c, 33590-12-4-o Attorney for the City of Laval. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 1993 L'Excellence, Compagnie d'Assurance-Vic Avis est par les présentes donné que « L'Excellence, Compagnie d'Assurance-Vie », de la ville de Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, à la présente session, pour la passation d'une loi permettant à ladite compagnie de restructurer son capital-actions.Donné à Montréal, ce 18 février 1970.Les ¦procureurs de la requérante.Deschênes, De Grandpré, Colas, 335S9-1 l-4-o Godin & Lapointe.I.a Communauté des Soeurs de Charité de La Providence Avis est, par les présentes, donné que « La Communauté des Soeurs de Charité de La Providence », s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec ù sa présente session pour obtenir la passation d'une loi lui permettant dc modifier sa charte pour mieux définir ses pouvoirs et ses droits et lui accordant certains autres pouvoirs nécessaires à une corporation religieuse.Montréal, le 4 mars 1970.Les procureurs de la requérante, Monette, Filion, Clerk, Miciiaud, 33615-1 l-4-o Harakett ct Lévesque.The Excellence Life Insurance Company Notice is hereby given that \"The Excellence Life Insurance Company\", of the city of Montreal, in the judicial district of Montreal, will apply to the National Assembly of Québec, at its present session, for the passing of an Act permitting the said Corporation to modify its capital structure.Given at Montreal, this February 18, 1970.Deschênes, De Grandpré, Colas, Godin & Lapointe, 33589-11-4-0 Attorneys for Petitioner.La Communauté des Soeurs de Charité de La Providence Notice is hereby given tliat \"La Communauté des Soeurs dc Charité de La Providence\", will apply to the National Assembly at its present session for thc passing of an Act allowing it to modify its charter in order to precise its powers and rights and granting it other powers necessary for a religious corporation.Montreal, March 4, 1970.Monette, Filion, Clerk, Miciiaud, Harakett and Lévesque, 33615-1 l-4-o Attorneys for thc petitioners.Vente d'effets non réclamés Messageries Canadien Pacifique Avis est par les présentes donné que tous les effets reçus avant lc 1er jour dc juin 1969, et non réclamés aux bureaux des Messageries Canadien Pacifique à divers endroits de la province dc Québec, seront vendus aux enchères publiques au plus haut enchérisseur par Frank Wnddington, encanteur, 189 est rue Queen, Toronto, Ontario, à onze heures du matin, lc 7c jour de mai 1970, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.La Cie des Messageries Canadien Pacifique.Le vice-président et gérant-général, 33616-11-6-0 W.J.Bowers.Sale of Unclaimed Goods Canadian Pacific Express Company Notice is hereby given that all goods received previous to the 1st day of June, 1969, and still remaining unclaimed in the offices of the Canadian Pacific Express Company, at different points in the Province of Québec, will be sold at Public Auction to the highest bidder by Frank Wadding-ton, auctioneer, at 189 Queen Street East, Toronto, Ontario, at eleven o'clock in thc forenoon, on the 7th day of May, 1970, unless same shall be called for before that date, and all charges paid thereon.Canadian Pacific Express Company.W.J.Bowers, Vice-President 33616-11-6-0 and General Manager.Ministère de l'Education Department of Education Champlain Demande est faite de fusionner le territoire actuel des municipalités scolaires de Limbour « C >, dans lc comté de Hull, et Pointe-Gatineau, dans le comté de Gatineau, et dc l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom dc Champluin, dans les comtés de Gatineau et Hull.Québec, le 17 mars 1970.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.33770-12-2-o 610-04 Champlain Application is made to amalgamate the present territory of the school municipalities of Limbour \"C\", in thc county of Hull, and Pointc-Gatincau, in the county of Gatineau, and to erect it into a new school municipality under the name of Cham-plain, in the counties of Gatineau and Hull.Québec, March 17, 1970.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.33770-12-2 610-04 Gatineau Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire du village de Temple-Ion, dans le comté de Hull à la municipalité scolaire de Gatineau, dans lc comté de Hull.Québec, le 16 mars 1970.I.c ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.33771-12-2-0 610-03 Gatineau Application is made to annex the present territory of the school municipality of the village of Templeton, in the county of Hull to thc school municipality of Gatineau, in the county of Hull.Québec, March 16, 1970.Jean-Guy Cardinal, .Minister of Education.33771-12-2 610-03 1994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 18 Granby Dcmuutlc est faite d'annexer le territoire actuel des municipalités scolaires de Saint-Alphonse-de-Granby, Saintc-Cécile-de-Milton et Sainte-Pu-dentienne, dans le comté de Shefford, à la municipalité scolaire de Granby, dans le comté de Shefford.Québec, le 17 mars 1970.Ixt ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.33772-12-2-0 520-03 Granby Application is made to annex the present territory of the school municipalities of Saint-Alplion-se-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton and Sain-te-Pudenticnne, in the county of Shefford, to the school municipality of Granby, in the county 0f Shefford.Québec, March 17, 1970.Jean-Guy Cardinal Minister of Education.33772-12-2 520-03 Grande-Hermine Demande est faite dc fusionner lc territoire actuel des municipalités de Murdochville, dans le comté de Gaspé-Nord, Cap-Aux-Os, Douglastown « C », Gaspé « C », Rang St-Paul, Saint-Georgcs-de-Malbaie ct Saint-Marjorique, dans le comté dc Gaspé-Sud, et dc l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom de Grande-Hermine, dans les comtés de Gaspé-Xord et Gaspé-Sud.Québec, le 17 mars 1970.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.33773-12-2-0 045-04 Grande-Hermine Application is made to amalgamate thc present territory of thc municipalities of Murdochville, in the county of Gaspc North, Cap-Aux-0s, Douglastown \"C\", Gaspé \"C\", St-Paul Rangé, Saint-Gcorges-dc-Mnlbaic and Saint-Marjoriquc, in the county of Gaspé South, and to erect it into a new school municipality under thc name of Grande-Hermine, in thc counties of Gaspé North and Gaspé South.Québec, March 17, 1970.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.33773-12-2 045-04 Havre Sl-Pierrc Demande est faite de fusionner le territoire actuel des municipalités scolaires d'Aguanish, Baie John Beetz, Havre St-Pierrc, Longuc-Poin-te-de-Mingan, Magpie et Rivière St-Jean, dans le comté de Duplessis, et de l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom de Havre St-Pierrc, dans lc comté de Duplessis.Québec, lc 17 mars 1970.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.33774-12-2-o 175-04 Havre St-Pierre Application is made to amalgamate thc present territory of the school municipalities of Aquuuish, Baie Jolin Bcetz, Havre St-Picrre, Longue-I'ointe-dc-Mingan, Magpie and Rivière St-Jenn, in the county of Duplessis, and to erect it into a new school municipality under thc name of Havre St-Pierre, in the county of Duplessis.Québec, March 17, 1970.Jean-Guy Cardinal.Minister of Education.33774-12-2 175-04 Manicouagan Demande est faite de fusionner le territoire actuel des municipalités scolaires de Baie-Co-ineau, Baie-Trinité, du Village dc Chute-Aux-Outardcs, Village de Godbout, Hautcrivc, Pointe Lebcl et Raguencau, dans le comté dc Saguenay, ct dc l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous lc nom de Manicouagan.dans le comté de Saguenay.Québec, le 17 mars 1970.Iœ ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.33776-12-2-0 140-05 Manicouagan Application is made to amalgamate thc present territory of the school municipalities of Baic-Conicau, Baie-Trinité, thc Village of Chute-Aux-Outardes, Village of Godbout, Hautcrivc, Pointé Lebel and Raguenau, in the county of Saguenay, and to erect it into a new school municipality under the name of Manicouagan.in the county of Saguenay.Québec, March 17, 1970.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.33770-12-2 140-05 Témiscaminguc Demande est faite dc fusionner lc territoire actuel des municipalités scolaires dc Béarn, la Ville de Belleterre, Fabre, Laforce, Latulippe, La-verlochère, Mont-Carmel, Nédelec, Notre-Damc-de-Lourdes, Notre-Dame-du-Nord, Saint-Bruno-dc-Guigucs, Saint-Eugène-de-Guigues, Saint-Ro-iniiald i le - Moffet, Saint-Viateur-d'Ançliers et Ville-Marie, dans le comté de Témiscamingue, et de l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom de Témiscamingue, dans le comté de Témiscamingue.Québec, le 17 mars 1970.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.33779-12-2-q 145-02 Témiscamingue Application is made to amalgamate the present territory of thc school municipalities of Beam, the Town of Belleterre, Fabrc, Laforce, Latulippe, Laverlochère, Slont-Carmcl, Nédelec.Notre-Damc-dc-Lourdcs, Notre-Dame-du - Nord, Saint-Bruno-dc-Guigues, Saint-Eugènc-dc-Gui-gues, Saint-Romuald-dc-Moffet, Saint-Viatcur-d'Angliers and Ville-Marie, in the county ol Témiscamingue, and to erect it into a new school municipality under the name of Témiscamingue.in the county of Témiscamingue.Québec, March 17, 1970.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.33779-12-2 145-02 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 Matanc Demande est faite «le fusionner le territoire actuel des municipalités scolaires de Baic-des-Sablcs, Grosses-Roches, Matane, Saint-Adelmc, Saint -Luc ct Saint-Ulric, dans le comté de Matane.et de l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom dc Matane, dans le comté de Matane.Québec, lc 16 mars 1970.Le minisire de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.33777-12-2-0 595-01 Pontiac Demande est faite de fusionner le territoire actuel îles municipalités scolaires dc Davidson, Fort-Coulonge « C », Ilc-aux-Allumettes-Est, Sheen ct Waltham, dans lc comté de Pontiac, et de l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous lc nom de Pontiac, dans le comté dc Pontine Québec, lc 17 mars 1970.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.3377S-12-2-0 610-05 Ministère des Terres et Forêts Cadastre Canton de Granby Cadastre officiel du canton dc Granby, municipalité dc la Cité dc Granby, division d'enregistrement de Shefford.Avis est par la présente donné que la partie restante du lot 633-32 est annulée en vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, le 6 février 1970.Ix sous-minislre, 33855-ci Ferxand Boutin.Partie «le l'Ile du Cap-aux-Mcules (revisé) Cadastre officiel d'une partie dc l'Ile du Cap-aux-Mcilles (revisé), municipalité du village de Cap-aux-Mcules, division d'enregistrement des Iles de la Madeleine.Avis est par la présente donné que les lots I470A.1479B, 1481A, 1483A, 1483B, 1488A, 1490A.1567A, 1567B.1579A.1598A à 1598D.I612A, 1621 A, 1826A.1826B et 1845A sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 12 février 1970.Le tous-ministre, 33855-0 Fern and Boutin.Canton Loranger Cadastre officiel «lu Canton Loranger, municipalité du Village «le Nominingue, division d'enregistrement «le Labelle.Avis est par la présente donné que lc bloc « B » rst ajouté en vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, le 26 février 1970.Le sous-ministre, 33855-n Fernand Boutin.Village dc Mont-Laurier Cadastre officiel du village de Mont-Laurier, municipalité de la Ville de Mont-laurier, division d'enregistrement «le Labelle.1995 Matane Application is made to amalgamate the present territory of thc school municipalities of Baie- des-Sables, Grosses-Roches, Matanc, Saint-Adelme, Saint-Luc and Saint-Ulric, in the county of Matane, and to erect it into a new school municipality under the name of Matanc, in the county of Matane.Québec, March 16, 1970.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.33777-12-2 595-01 Pontiac Application is made to amalgamate the present territory of the school municipalities of Davidson, Fort-Coulonge \"C\", Ilc-aux-AUumettes-East, Sheen and Waltham, in thc county of Pontiac, and to erect it into a new school municipality under the name of Pontiac, in thc county of Pontiac.Québec, March 17, 1970.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.33778-12-2 610-05 Department of Lands and Forests Cadastre Township of Granhy Official cadastre of township of Granby, municipality of thc City of Granby, registration division of Shefford.Notice is hereby given that thc remaining part of lot 633-32 is cancelled in virtue of Article 2174A of thc Civil Code._ Québec, February 6, 1970.Fernand Boutin, 33855-0 Depuly Minister.Part of l'Ile du Cap-aux-Mcules (Revised) Official cadastre of u part of \"l'Ile du Cap-aux-Mcules\" (Revised) municipality of Village of Cap-aux-Mcules, registration division of lies de la Madeleine.Notice is hereby given that lots 1479A, 1479B, 1481 A, 1483A, 1483B, 1488A.1490A, 1567A, 1567B, 1579A, 159SA to 1598D.1612A, 1621A, 1826A, 1826B and 1S45A arc added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, February 12, 1970.Fernand Boutin.33855-0 Depuly Minister.Township of I-orangcr Official cadastre of township of Loranger, municipality of Village of Nominingue, registration division of Labelle.Notice is hereby given that block \"B\" is added in virtue of Article 2174A of Civil Code.Québec, February 26, 1970.Fernand Boutin, 33855-0 Depuly Minister.Village of Mont-Luuricr Official Cadastre of Village of Mont-Laurier, municipality of the town of Mont-Lauricr, registration division of Labelle. 1990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n\" 13 Avis est par la présente donné que les lots 1863 et 1864 sont ajoutes et que les lots 570 à 580 et qu'une partie des lots 563, 581, 582, 585 et 586 sont annulés en vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, lc 5 mars 1970.Le sous-minislre, 33855-0 Fernand Boutin.Canton dc Robcrval Cadastre officiel du canton de Roberval, municipalité de la cité de Roberval, division d'enregistrement dc Lac St-Jenn Ouest.Avis est par la présente donné que les lots 58-14, 58-17 à 58-19, 58-23 à 58-29 ct que la partie restante des lots 58-13, 58-20 à 58-22 et 58-30 sont annulés en vertu dc l'article 2174A du Code Civil.Québec, le 2 décembre 1969.Le sous-minislre, 33855-o Fernand Boutin.Paroisse de Sl-Antoine de Longueuil Cadastre officiel dc la paroisse dc St-Antoinc dc Longueuil, municipalité de la ville de Longueuil, division d'enregistrement dc Chambly.Avis est par la présente donné que les lots 125-100, 125-96 (ruelles) et 125-108 (rue) sont annulés en vertu dc l'article 2174A du code civil.Québec, le 2 mars 1970.Le sous-minislre, 33855-o Fernand Boutin.Paroisse de St-Jean Cadastre officiel de la paroisse dc St-Jean, municipalité de la paroisse dc St-Jcan l'Évan-géliste, division d'enregistrement dc St-Jcan.Avis est par la présente donné que les lots 47-8-2 à 47-8-11 inclusivement ct qu'une partie du lot 47-8 sont annulés en vertu de l'article 2174A du code civil.Québec, le 6 mars 1970.Le sous-minislre, 33855 Fernand Boutin.Canton de Tcmplcton Cadastre officiel du canton de Tcmplcton, municipalité dc Templeton-est*, division d'enregistrement de Hull.Avis est par la présente donné que dans le rang 11, une partie des lots 5B, 5C, 5D et du chemin (Main Road) est annulée et que lc lot 5Q est ajouté en vertu dc l'article 2174A et dc l'article 7 du code civil.Quél»cc, lc 5 mars 1970.Le sous-minislre, 33855-0 Fernand Boutin.Notice is hereby given that lots 1863 and 1864 arc added and that lots 570 at 580 and a part of lots 563 581, 582, 535 and 536 are cancelled in virtue of Article 2174A of thc Civil Code.Québec, March 5, 1970.33855-0 Fernand Boutin, Depuly Minister.Township of Robcrval Official cadastre of township of Robcrval, municipality of the city of Roberval, registration division of Lac St-Jcan Ouest.Notice is hereby given that lots 58-14, 5S-17 to 58-19, 58-23 to 58-29 and that a remaining part of lots 58-13, 58-20 to 58-22_and 5S-30 are cancelled in virtue of article 2174A of the Civil Code.Québec, December 2, 1969.Fernand Boutin.33855-0 Depuly Minister.Parish of St-Antoinc de Longueuil Official cadastre of the parish of St-Antoinc de Longueuil, municipality of the town of Longueuil, registration division of Chamhly.Notice is hereby given that lots 125-100.125-96 (lanes) and 125-108 (street) are cancelled in virtue of article 2174A of the Civil Code.Québec, March 2, 1970.Fernand Boutin, 33855-0 Depuly Minister.Parish of St-Jcan Official cadastre of the parish of St-.lean, municipality of the parish of St-Jean l'Rvungélistc, registration division of St-Jcan.Notice is hereby given that lots 47-S-2 to 47-8-11 inclusively and a part of lot 47-S are cancelled in virtue of article 2174A of the Civil Code.Québec, March 6, 1970.Fernand Boutin.33855 Depuly M initier.Township ol' Templetn Official cadastre of township of Tcmplcton, municipality of Tcmplcton-enst*, registration division of Hull.Notice is hereby given that in the range 11.a part of lots 5B, 5C, 5D nnd the road (Main Road) is cancelled and that lot 5Q is added in virtue of article 2174A and the article 7 of the Civil Code.Québec, March 5, 1970.Fernand Boutin.33855-0 Depuly M in Mer.Arrêtés en Conseil Orders in Council Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 462 Québec, le 4 février 1970.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les pouvoirs de la Régie des loteries ct courses en matière de systèmes de loteries ct les modalités selon lesquelles des licences peuvent être délivrées.Order in Council Executive Council Chamber Number 462 Québec, February 4, 1971).Present: The Lieutenant-Governor in Council Respecting thc powers of the Régie des loterie* d courses respecting lottery schemes and the conditions upon which licences may be issued. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 1997 Vu l'article 21 du bill 86, lois de 1969, entré en vigueur le 23 janvier 1970; Vu la nomination des membres de la Régie des loteries et courses le 23 janvier 1970; Attendu Qu'en vertu dudit article, la Régie des loteries ct courses du Québec peut, si le lieutenant-gouverneur en conseil lui en confie le pouvoir, délivrer des licences autorisant des personnes à conduire et administrer des systèmes (le loteries conformément à la Loi et aux modalités prescrites par lc lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu de confier ledit pouvoir à cette Régie ct de prescrire les modalités appropriées; ii, est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre dc la justice: Que la Régie des loteries ct courses du Québec soit autorisée ù délivrer des licences autorisant des personnes à conduire ct administrer des systèmes dc loteries conformément aux règlements.Que le règlement numéro 1 relatif aux licences pour systèmes dc loteries et dont copie est annexée à la proposition susdite soit approuvé et décrété en vigueur pour une période provisoire de six mois.Le greffier du Conseil exécutif, Julien Chouinard.RÉGIE DES LOTERIES ET COURSES DU QUÉBEC Règlement numéro 1 Relatifs aux licences pour systèmes de loteries Lc lieutenant-gouverneur en conseil décrète ct ordonne: 1.En plus des pouvoirs qui lui sont attribués pur la Loi sur les loteries et courses, la Régie des loteries cl courses du Québec (ci-après dénommée ' La llégie »), créée en vertu de cette même loi, a en outre, tel que prévu au deuxième alinéa dc l'article 21 de ladite loi, le pouvoir de délivrer des licences autorisant des personnes à conduire et administrer des systèmes de loteries ct elle peut eu conséquence délivrer des licences aux lins d'autoriser: a) un organisme de charité tnt un organisme religieux il conduire ct administrer un système de loterie au Québec \u2014 et, à cette fin, toute personne, sous l'autorité de cette licence, à faire toute chose visée dans l'un des alinéas a) à g) du paragraphe (1) ou au paragraphe (4) de l'article 179 du Code criminel, sauf en ce qui concerne un jeu dc dés, dc bonneteau, de planche ù trous (punch board) ou de table à sous, (i) si le produit du système de loterie est utilisé pour des fins ou oeuvres charitables ou religieuses, et (ii) si, dans le cas d'un système de loterie conduit par un organisme de charité ou un organisme religieux dnns une vente de charité, (A) le montant ou la valeur de chaque prix attribué ne dépasse pas cent dollars, (lt) et l'argent ou autre valeur payé pour obtenir une chance dc gagner un prix ne dépasse pas cinquante cents; b) une foire ou exposition agricole, ou un exploitant d'une concession donnée à bail par le conseil d une foire ou exposition ngricole, ù conduire ct administrer un système de loterie nu Québec Considering section 21 of Bill 86, statutes' of 1969, which came into force on the 23rd of January 1970; Considering thc appointment of the members of the Régie des loteries et courses on the 23rd of January 1970; Whereas under the said section the Régie des loteries et courses du Québec may, if the Lieutenant-Governor in Council entrusts to it the power, issue licences authorizing persons to conduct and manage lottery schemes in accordance with the law and the terms and conditions presented by the Lieutenant-Governor in Council; Whereas it is expedient to entrust such power to the Board nnd to prescribe the appropriate terms and conditions; It is ordered consequently, upon the proposal of the Minister of Justice: That thc Régie des loteries et courses du Québec be authorized to issue licences authorizing persons to conduct and mnnngc lottery schemes in accordance with the regulations.That regulation numlicr 1, respecting licences for lottery schemes, a copy whereof is annexed to the above proposal, lie approved and ordered to lie in force for a provisional period of six months.Julien Chouinhad, Clerk of the Executive Council.RÉGIE DES LOTERIES ET COURSES DU QUÉBEC Regulation nimber 1 Respecting licenses for lottery schemes The Lieutcnnnt-Govcrnor in Council orders: (1) In addition to the powers conferred upon it by the Lotteries and Races Act, the Régie des loteries cl courses du Québec, hereinafter colled \"the Board\", constituted under the said act shall have, as provided in thc second paragraph of section 21 of the said act, the power to issue licences authorizing persons to conduct nnd manage lottery schemes and, accordingly, it_ may issue licences for the purposes of authorizing: (a) charitable or religious organizations to conduct and manage a lottery scheme in Québec \u2014 and for such purpose, any person under the authority of such licence to do any thing contemplated in any of paragraphs « a » to * g » of subsection (1) or subsection (4) of section 179 of the Criminal Code, except as regards dice games, three-card monte, punch board or coin table, if (i) the proceeds from the lottery scheme are used for B charitable or religious object or purpose, and (ii) in the case of a lottery scheme conducted by a charitable or religious organization at a bazaar, (A) the amount or value of each prize awarded docs not exceed one hundred dollars, and (B) the money or other valuable consideration paid to secure a chance to win n prize docs not exceed fifty cents, (b) an agricultural fair or exhibition, or an operator of n concession based by an agricultural fair or exhibition board, to conduct and manage a lottery scheme in the province of Québec. 199S GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n* 18 \u2014 ct, ù cette fin, toute personne, sous l'autorité de cette licence, à faire toute chose visée dans l'un des alinéas a) à f) du paragraphe (1) ou au paragraphe (4) de l'article 179 du Code criminel; c) el toute personne, ù conduire ct administrer un système de loterie dans un lieu d'amusement public nu Québec \u2014 et, à cette fin, toute personne, sous l'autorité dc cette licence, à faire toute chose visée dans les alinéas a) à g) du paragraphe (1) ou au paragraphe (4) dc l'article 179 du Code criminel, sauf en ce qui concerne un jeu de «lés, de bonneteau, «lc planche à trous (punch board) ou dc table ù sous, (i) si lc montant ou la valeur «le chaque prix attribué ne dépasse pas «-ent dollars, (ii) ct si l'argent ou autre valeur payé pour obtenir une chanrc dc gagner un prix ne dépasse pas cinquante cents.2.En plus «l'être soumis aux conditions édictées dans le présent règlement, le pouvoir d'émettre des licences conféré à la Régie aux termes dc l'article 1 du présent règlement, est soumis mutatis mutandis aux dispositions des articles 22 a 25 dc la Loi sur les loteries et courses, bill 86 des lois de 1969, ainsi qu'aux autres modalités ou conditions qui pourront être édictées de temps ii autre pnr le licutcnunt-gouvcrncur en conseil.3.Sous réserve des dispositions du présent règlement, la Régie peut délivrer à tout requérant une licence pour conduire ct administrer un ou «les systèmes dc loteries conformément aux modalités ct conditions é«lictées au présent règlement ninsi qu'il celles que la Régie peut sj-écifier en vertu des dispositions contenues au présent règlement.4.a) Une licence peut être délivrée pour plus d'un système dc loteries, s'ils sont dc même catégorie ct s'ils doivent être conduits en entier par lc même détenteur dc licence, uu même lieu, durant le même jour ou In même période, ct aux mêmes fins.6) Si une licence est délivrée pour plus d'un système dc loteries, elle doit contenir «les indications suffisantes sur chaque système, ct mentionner cluirement qu'elle est valable pour chacun d'eux.5.Toute demande de licenœ doit être faite par une personne physique en son nom personnel ou au nom d'une corporation.Si plusieurs personnes font une demande conjointe, cette demande doit être signée par chacune d'elles.En outre, dans lc cas d'une corporation, la demande doit être appuyée d'une copie certifiée de la résolution dc la corporation autorisant les personnes requérantes ù signer à cette fin; cette résolution doit indiquer lc nom dc la personne nu nom de qui lu licence doit être délivrée pour lc bénéfice île la corporation.6.Toute personne qui fait une demande de licence doit dans sa requête, en plus de tout autre renseignement que peut exiger la Régie, spécifier: a) Lc nom, l'adresse, l'occupation, le numéro «le téléphone et la date et lieu «le naissance du requérant; b) Une description des règles du système dc loterie pour lequel la licence est demandée; c) S'il y a lieu, l'adresse et le nom dc la salle où «loit se tenir la réunion ainsi que le nom, l'adresse ct le numéro dc téléphone du propriétaire de l'immeuble où est située la salle; \u2014 and, for such purpose, any person under the authority of such license to do any thing contemplated in any of paragraphs (a) to (/) of subsection 1 or subsection 4 of section 179 of the Criminal Code; (r) and any person to conduct and manage a lottery scheme at a public place of amusement in thc province of Québec.\u2014 and for such purpose any person, under thc authority of such licence to do any thing contemplated in pnragraph (a) to (g) of subsection 1 or subsection 4 of section 179 of the ( 'rimi.nal Code, except as regards dice games, three-card monte, punch board or coin table, if (i) thc amount or value of each prize awarded does not exceed one hundred dollars, and (ii) the money or other valuable consideration paid to secure a chance to win does not exceed fifty cents.2.Thc power to issue licences, conferred ii[>on thc Hoard by nrticlc 1 of this regulation, shall, l>esides l)eing subject to thc conditions herein ordered, l>c subject mutatis mutandis to sections 22 to 25 of thc lotteries and Races Act.Hill S6 of thc statutes of 1969, and to such other terms and conditions as may be ordered from lime to tome by thc Lieutenant-Governor in Council, 3.Subject to this regulation, the Hoard may issue a licence to conduct and manage one or more lottery schemes to any applicant in accordance with the terms and conditions hereby ordered and with such others as the Hoard may specify under this regulation.4.(a) A licence may Ix- issued for several lottery schemes if they are of thc same class and if they are to be conducted entirely by I lie same licensee, at thc same place, on the same day or at thc same time, and for thc same purposes.(6) If a licence is issued for several lottery schemes, it must contain sufficient information respecting each scheme and clearly indicate that it is valid for each scheme 5.Every application for a licence must lie made by a physical person in his own name or in thc name of a corporation.If several persons make a joint application, it must be signed by each of them.Also, in the case of a corporation, the application must be accompanied by a certified copy of thc corporation's resolution authorizing the applicants to sign for such purpose: such resolution must indicate thc name of the person to whom the licence is to be issued for the benefit of the corporation.6.Every person applying for a licence must state, in addition to any other information which the Board may require, (a) the name, address, occupation, telephone number and date and place of birth of the applicant; (b) a description of the rules of the lottery scheme respecting which thc licence is applied for; (c) if necessary, the address and name of He hall where thc meeting is to be held, and the name, address and telephone number of the owner of the immovable where the hall is located: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 1999 ,/) Le nombre approximatif de personnes qui participeront il la réunion, le cas échéant; c) l,c nombre de systèmes de loteries auxquels les joueurs seront appelés il participer, le prix de vente de chaque chance de gagner un prix et la valeur «le chaque prix devant être attribué aux gagnants dc chaque système; /) L'heure, la date ct le lieu où commenceront chaque système de loteries et la réunion a cette fin, le cas échéant, ainsi que l'heure, la date et le lieu dc la clôture «lc chaque système ct de la réunion, lc cas échéant; g) Le nombre «le chances dc gagner un prix pour chaque système; h) Lc lieu, lu «latc ct l'heure «lu tirage au sort des prix ou des lots ù gagner; i) S'il s'agit d'un système de loterie pour «les fins ou oeuvres religieuses ou de charité, une description sommaire de ces fins ou oeuvres; j) Si les lots sont en nature, une description sommaire dc ces lots avec indication dc leur valeur respective.7.Avec sa requête, le requérant doit payer en argent, par mandat ou chèque visé ù la Régie un honoraire «le $10 pour chaque licence.S.Lors du dépôt «le sa requête, le requérant doit signer un engagement dc faire par écrit n la Régie un rapport complet sur lc système «le loterie qu'il conduira, ct cela dans les quinze jours après la date fixée pour l'attribution des lois au hasard; ce rapport doit entre autres indiquer les recettes et déboursés, lc nombre et la valeur des prix attribués aux gagnants, lc nom et l'adresse dc ces derniers, lc nom et l'adresse d'au moins trois témoins du processus dc collation des chances «le gagner un prix et du tirage au sort qui suit, le nombre «le billets vendus et le nombre «le billets non vendus.!).Dans lc cas où lc détenteur d'une licence fait défaut dc soumettre ù la Régie le rapport prévu à l'article 8, lc dépôt «le cautionnement, s'il en a été exigé, est confisqué ct aucune licence ne peut lui être accordée jusqu'il ce qu'il se soit conformé aux exigences du présent règlement ainsi qu'à celles que la Régie peut déterminer; il en sera dc même dans lc cas où il est établi à la satisfaction de la Régie que les conditions et modalités de la délivrance d'une li«-encc n'ont pas été observées.La somme déposée en cautionnement peut être remise nu détenteur de licence lorsque la Régie se «léclarc satisfaite de ce «pic ces prescriptions ct les siennes sont dûment remplies.10.Avant dc délivrer une licence, In Régie peut ù sa discrétion convoquer le requérant ou toute personne dont clic a sujet d'obtenir des renseignements utiles, et mener toute enquête qu'elle jugera nécessaire.Elle peut alors, si elle lc juge à propos pour la protection du public, exiger un dépôt dc cautionnement suffisant pour payer les prix que le système de loterie prévoit comme devant être attribués aux gagnants.11.En outre des recours par lc Procureur général, après avoir délivré une licence, la Régie peut, si elle juge dans l'intérêt public dc lc faire, retirer la licence, ordonner la discontinuation du système dc loterie, confisquer les argents recueillis de même que la somme déposée en cautionnement, si elle en a exigé une, procéder nu tirage au sort des gagnants et leur attribuer les prix conformément au système en entier ou au prorata dans le eus où les deniers confisqués sont insuffisants.(c awarded to thc winners in each scheme; (/) thc date, time and place of thc commencement of each lottery scheme and, if need be, of the meeting for such purpose, and the date, time nnd place of thc closing of each scheme anil of thc meeting; if need be; (j?) thc number of chances to win a prize in each scheme; (//) thc place, date and time of thc drawing of thc prizes to be won; (t) in thc case of a lottery scheme for religious or charitable purposes or objects, a summary description of such purposes or objects; (j) if the prizes are in kind, a summary description of such prizes with an indication of their respective values.7.With his application thc applicant must pay in cash, by a money order or cheque payable to the Board, a fee of 810 for each licence 8.At thc time of thc filing of his application, the applicant shall sign an undertaking to make a complete written return to the Board on the lottery scheme which he will conduct, within fifteen days after the date fixed for thc awarding of thc prizes by lot; such return shall indicate, inter alia, receipts and disbursements, the number nnd value of the prizes awarded to the winners, thc names and addresses of thc winners, the names nnd addresses of at least three persons who witnessed the method of grunting chances to win a prize and the subsequent drawing by lots, the number of tickets sold and thc number of tickets unsold.9.If u licensee fails to submit thc return provided for in article 8 to the Board, the «ieposit of security, if any lins been required, shall be confiscated un«l no licence shall be issued to him until be has complied with the requirements of this regulation and with such requirements as the Board may determine; the same shall apply in cases where it is established to the satisfaction of the Bourd that the terms nnd conditions for the issue of a licence have not been met.The amount deposited as security may be remitted to the licensee when the Board declares itself satisfied that such requirements, and its own requirements, have been fully complied with.10.Before issuing n licence, the Board, in its discretion, may convene the applicant or any person from whom it may obtain useful information, and conduct any inquiry which it may deem useful.It may then, if it so deems expedient for the protection of the public, require a «Ieposit of security sufficient to pay the prizes which the lottery scheme foresees will be distributed to the winners.11.In addition to the recourses by the Attorney-General, the Board, after it has issued a licence, may, if it deems it in the public interest to do so, withdraw the licence, order that the lottery scheme lie discontinued, confiscate the moneys collected and the amount deposited as security, if such an amount has been required, proceed with the drawing of the winners by lots nnd award prizes to them, in accordance with the scheme, in whole or pro rata in cases where the money confiscated is insufficient. 2000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 wars 1970, 102' année, n° 13 12.Lorsqu'une demande dc licence est faite pour une société, une copie certifiée dc l'enregistrement de cette dernière doit être déposée à la Régie avec la demande; dans le cas d'une corporation, le requérant doit déposer une copie certifiée de son acte d'incorporation.13.La Régie peut exiger que tout système de loterie soit conduit ct administré dans des lieux conformes à la loi ct aménagés suivant les règlements de construction, de salubrité ct de sécurité publiques décrétés par l'autorité municipale ou provinciale.14.La Régie peut faire enquête pour déterminer si les profits réalisés dans la conduite ct l'administration d'un système dc loterie ont été effectivement utilisés en tout ou en partie aux fins ou oeuvres pour lesquelles une licence a été délivrée.15.Le pourcentage minimum qui, de toutes recettes provenant d'un système dc loterie, doit être affecté par le détenteur d'une licence à la distribution en lots au public participant, doit être fixé par la Régie, mais il ne peut être inférieur à 10%.16.Le pourcentage maximum qui, des recettes d'un système dc loterie, doit être affecté par le détenteur d'une licence, à défrayer les frais d'administration, d'organisation et dc conduite de ce système de loterie, doit être de 15%.17.La Régie peut fixer la somme ou valeur maximum dc tous les lots à être attribués dans un système tic loterie.18.La Régie peut fixer le nombre maximum de toutes les chances dc gagner un lot dans un système dc loterie.19.La Régie peut fixer lc lieu, la date ct l'heure qu'elle croit appropriés pour lc tirage au sort des gagnants ou l'attribution des lots.Tout tirage au sort doit être public et fait devant au moins trois témoins.20.La Régie peut limiter lc nombre et la fréquence des licences ct des systèmes de loteries, selon qu'elle croit approprié, dans une région ou une municipalité par rapport u sa population.21.La Régie peut déterminer toutes nutres modalités ct conditions propres à assurer la protection du public ct l'ordre public.Québec, 4 février 1970.33824-0 Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 992 Québec, lc 11 mars 1970.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la soustraction au jalonnement de claims miniers sur certains terrains situés dans lc comté dc Laviolettc.Attendu qu'une étendue de terrain située ù l'ouest de la rivière St-Maurice et au nord dc la ville de Grand-Mère a été choisie conjointement par lc Gouvernement du Québec ct lc Gouvernement du Canada pour l'aménagement du parc dc la Mauricic; Attendu que le directeur général des parcs au ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche a demandé dc ne plus émettre dc claims miniers dans ce territoire; Attendu Qu'il y a lieu de prévenir tout jalonnement dans le secteur prévu pour l'aménagement dudit parc; 12.Where an application for a licence is made on behalf of a partnership, a certified copy of the registration of such partnership must be filed with the Board along with the application; in the case of a corporation, the applicant must dc-posit a certified copy of its instrument of incorporation.13.The Board may require tliat every lottery scheme be conducted and managed in surroundings which comply with thc law and arc equipped in accordance with the building, health anil public safety by-laws or regulations passed by provincial or municipal authority.14.The Board may conduct an investigation to determine whether the profits realized in the conducting and management of a lottery scheme have been actually used, in whole or in part, for the purposes or objects for which a licence has lieen issued.15.The minimum percentage of all the receipts of a lottery scheme to be set aside by a licensee for distribution as prizes to the participating public must be fixed by the Bonrd but shall not be less than 10%.16.The maximum percentage of the receipts of a lottery scheme to be set aside by a licensee to pay the cost of the management, organization and conducting of such lottery scheme must lie 15%.17.The Board may fix the maximum total or value of all prizes to be awarded in a lottery .scheme 18.The Board may fix the maximum number of all chances to win a prize in a lottery scheme.19.The Board may fix such place, day and hour as it deems appropriate for the drawing of winners by lots or for the awarding of prizes.Any drawing shall be public and must be effected before at least three witnesses.20.The Board may restrict the number and frequency of licences and lottery schemes, as it deems appropriate, in relation to the population of any region or municipality.21.The Board may determine any other terms and conditions necessary to ensure public order and the protection of the public.Québec, February 4, 1970.33824-0 Order in Council Executive Council Chamber Number 992 Québec, March 11, 1070.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the withdrawal from staking of mining claims on certain lands situated in the county of Laviolettc.Whereas a strip of land situated west of St-Mouricc River and north of thc town of Grand-Mère was chosen jointly by the Québec Government and the Government of Canada for thc development of the Mauricic Park; Whereas the general director of parks at the Department of Tourism, Fish and Game requested that mining claims on this territory no longer be issued; Whereas it is expedient to prevent any staking on the sector provided for the development of the said park; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 2001 attendu que, conformément au paragraphe 1) de l'article 268 de la Loi des mines (13-14 Elizabeth IL cliapitrc 34), le Lieutenant-gouverneur en conseil peut_ réserver ct soustraire par règlement tout terrain qui, dans son opinion, peut être nécessaire à l'établissement d'ateliers de traitement, d'usines de fonte, d'affinerics ou de voies de transport, ou à l'aménagement dc forces hydrauliques ou à l'emmagasinemcnt d'eau, ou à toutes autres fins.Il, est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Richesses naturelles: Qi'K soient réservés ct soustraits à la prospection ct au jalonnement en claims miniers les terrains ci-après décrits couvrant une superficie approximative de 165,000 acres: Une étendue de terrain situés dans les districts électoraux de Laviolctte et de St-Maurice ctplus particulièrement décrite comme suit : Partant d'un point situé sur la rive ouest de la rivière St-Maurice sur la ligne separative des lots (' ct D du rang I du canton dc Radnor; de là, dans une direction générale nord-ouest, nord-est et nord-ouest en suivant la rive ouest de la rivière St-Maurice jusqu'à l'embouchure de la rivière Mata win; de là, vers lc nord-ouest ct le sud-est en suivant la rive sud de la rivière Matawin, jusqu'au milliaire lm ct 9.93 chaincs sur la ligne separative des districts électoraux dc Laviolettc ct de St-Maurice; de là, dans une direction sud-oucsl jusqu'à un point situé à l'intersection dc la latitude nord 46°49' et de la longitude ouest 73°09'20\"; dc là, vers le sud-est jusqu'à un point situé à l'intersection de la latitude nord 46°4S' ct dc la longitude ouest 73°09'; dc là, dans une direction sud-est jusqu'à un point situé à l'intersection dc la latitude nord 46°45'30\" ct de In longitude ouest 73°07'20\"; dc là, dnns une direction sud-est jusqu'à un point situé à l'intersection de la latitude nord 46°44'15\" ct de la longitude ouest 73°04'30\"; dc là, dans une direction sud-est jusqu'à un point situé au milliaire 10 sur la ligne separative des cantons Belleau ct Desaulniers; de là, en ligne droite dans une direction sud-est jusqu'à un point situé sur la limite nord-ouest du canton dc Caxton sur la ligne separative des rangs XI et XII dudit canton; dc là, vers lc nord-est en suivant la limite nord-ouest du canton dc Caxton jusqu'à un point situé sur la ligne separative des rangs XII et XIII dudit canton; dc là, vers lc sud-est en suivant la ligne separative des rangs XII et XIII du canton de Caxton jusqu'à un point situé au coin sud du lot 12 dudit rang XIII; de là, vers lc nord-est en suivant la limite sud-est du lot 12 du rang XIII du canton dc Caxlon jusqu'au coin nord du lot 11 du rang XIII dudit canton; de là, vers le sud-est en suivant la ligne separative des rangs XIII ct XIV jusqu'au coin sud du lot 10 dudit rang XIV; de là, vers lc nord-est en suivant la limite sud-est du lot 10 du rang XIV du canton dc Caxton jusqu'à la ligne léparative des rangs XIV et XV dudit canton; de là, vers le sud-est en suivant la ligne separative (les rangs XIV ct XV du canton dc Caxton jusqu'au coin sud du lot 7 dudit rang XV; dc là, dans une direction nord-est en suivant la limite sud-est du lot 7 du rang XV du canton dc Caxton jusqu'à la ligne separative des rangs XV et XVI; de là, dans une direction sud-est en suivant la ligne separative des rangs XV et XVI du canton de Caxton jusqu'au coin sud du lot 4 dudit rang XVI; de là, dans une direction nord-est en suivant ¦a limite sud-est des lots 4 des rangs XVI ct XVII jusqu'à la ligne separative des rangs XVII et Whereas, in conformity with paragraph 1) of section 268 of the Mining Act (13-14 Elizabeth II, chapter 34), the Lieutenant-Governor in Council may reserve and withdraw by regulation any land which, in lus opinion, may be necessary for thc establishment of mills, smelters, refineries or means of transportation, or for the development of water power or water storage, or for any other purpose; Therefore, it is ordered, upon thc recommendation of thc Minister of Natural Resources: That the lands hereafter described covering an approximative area of 165,000 acres be reserved and withdrawn from prospecting and staking of mining claims.A strip of land situated in the electoral districts of Laviolettc and St-Mauricc and more fully described as follows: Starting from a point situated on the west shore of St-Mauricc River on thc separative line of lots C and D of range I of the township of Radnor; thence, in a general northwest direction, north-cast and northwest following the west shore of St-Maurice River to the mouth of Matawin River; thence, on the northwest and southeast following thc south shore of Matawin River, to the milestone lm and 9.93 chains on the separative line of thc electoral districts of Laviolettc and St-Mauricc; thence, in a southwest direction to a point situated at thc intersection of north latitude 46°49' and west longitude 73°09'20\"; thence, on thc southeast to a point situated at the intersection of north latitude 46°48' and west longitude 73°09'; thence, in a southeast direction to a point situated at the intersection of north latitude 46°45'30\" and west longitude 73°07'20\"; thence, in a southeast direction to a point situated at thc intersection of north latitude 46°44'15\" and west longitude 73°04'30\"; thence, in a southeast direction to a point situated on milestone 10 on the separative line of the townships of Belleau and Desaulniers; thence, in a straight line in a southeast direction to a point situated on the northwest limit of the township of Caxton on thc separative line of ranges XI and XII of the said township; thence, on thc northeast following the northwest limit of thc township of Caxton to a point situated on thc separative line of ranges XII and XIII of the said township; thence, on thc southeast following the separative line of ranges XII nnd XIII of the township of Caxton to a point situated on thc south corner of lot 12 of said range XIII; thence, on the northeast following thc southeast limit of lot 12 of range XIII of the township of Caxton to thc north corner of lot 11 of range XIII of thc said township; thence, on thc southeast following the separative line of ranges XIII and XIV to thc south corner of lot 10 of said range XIV; thence, on the northeast following thc southeast limit of lot 10 of range XIV of the township of Caxton to the separative line of ranges XIV and XV of the said township; thence, on thc southeast following thc separative line of ranges XIV and XV of the township of Caxton to the south corner of lot 7 of the said range XV; thence, in a north-cast direction following thc southeast limit of lot 7 of range XV of the township of Caxton to the separative line of ranges XV nnd XVI; thence, in a southeast direction following the separative line of ranges XV and XVI of the township of Caxton to thc south corner of lot 4 of said range XVI; thence, in a northeast direction following 2002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n\" 18 XVIII dudit canton; dc là, dans une direction sud-est en suivant la ligne separative des rangs XVII ct XVIII du canton de Caxton jusqu'uu coin sud du lot 1 du rung XVIII dudit canton; de là, vers le nord-est suivant la ligne nord-ouest du rang II du canton Shawinigan jusqu'au coin nord du lot 54 de cedit rang; dc là, vers lc sud-est en suivant la ligne separative des rangs I et II du canton de Shawinigan jusqu'au coin sud du lot 44 du rang I dudit canton; dc là, vers lc nord-est en suivant la ligne sud-est du lot 44 du rang I du canton dc Shawinigan et du lot 558 mentionné au cadastre dc la paroisse dc Stc-Florc jusqu'au coin est dudit lot 558; dc là, vers lc nord-ouest en suivant la ligne separative des rangs I et II de lu |>aroissc dc Stc-Flore jusqu'à l'extrémité ouest du lot 506 du cadastre de ladite paroisse; dc là, vers le nord-est en suivant la limite sud-est des lots 505, 485, 419, 3S1, 330 et 290 mentionnés uu cadastre de la paroisse de Stc-Flore, jusqu'à la limite nord-est dc ladite paroisse; de là, vers le sud-est en suivant la limite nord-est de la paroisse de Stc-Flore jusqu'au coin sud du lot D du rang I du canton de Radnor; de là, vers le nord-est en suivant la limite sud-est du lot 1) jusqu'au point de départ.Le tout tel qu'indiqué en rouge sur la carte régionale du ministère des Terres ct Forêts 2-Est à l'échelle dc 3 milles au |>ouce, lequel plan est initiale par le sous-ministre des Richesses naturelles ct fait partie des archives dc ce ministère.Que ce règlement ait force de loi à compter dc sa parution dans la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, 33854-0 Julien Chouinard.Arrêté en conseil Chumhrc du Conseil Exécutif Numéro 1231 Québec, le 18 mars 1970.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant lu prolongation du droit de prélèvement du Comité paritaire du Camionnage dc la région de Montréal.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail ct de la Main-d'œuvre: Que le droit dc prélèvement du Comité paritaire du Camionnage de la région dc Montréal, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 715 du 19 mars 1969, soit prolongé jusqu'au 31 niai 1970.aux mêmes taux et conditions.Le greffier du Conseil exécutif, 33856-0 Julien Chouinard.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1232 Québec, lc 18 mars 1970.Présent: I«c Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant lu prolongation du droit de prélèvement du Comité paritaire de l'alimentation de Chicoutimi.Il est ordonné, sur lu proposition de l'honorable ministre du Travail et dc la Main-d'oeuvre: the southeast limit of lots 4 of ranges XVI and XVII to thc separative line of ranges XVII and XVIII of thc said township; thence, in a southeast direction following the separative line of ranges XVII and XVIII of the township of Caxton to the south corner of lot 1 of range XVIII of the said township; thence, on the northeast following thc northwest line of range II of the township of Shawinigan to the north corner of lot 54 from this said range; thence, on thc southeast following thc separative line of ranges I and II of the township of Shawinigan to the south corner of lot 44 of range I of the said township; thence on the northeast following the .southeast line of lot 44 of range I of the township of Shawinigan and from lot 558 mentioned in the cadastre of the parish of Stc-Florc to thc east corner of said lot 558; thence, on the northwest following the separative line of ranges I and II of the parish of Stc-Florc to thc west extremity of lot 506 of the cadastre of the said parish; thence, on thc northeast following thc southeast limit of lots 505, 485, 419, 381, 330 and 290 mentioned on the cadastre of the parish of Stc-Florc to the northeast limit of the said parish; thence, on thc southeast following the northeast limit of thc parish of Stc-Florc to the south corner of lot I) of range I of the township of Radnor; thence, on the northeast following thc southeast limit of lot I) to the point of departure.The whole as indicated in red on the regional map of thc Department of Lands and Forests 2-East on a scale of 3 miles to an inch, the said plan initialed by thc Deputy Minister of Natural Resources and is part of thc Archives of this department.That this regulation come into effect from and after its publication in thc Québec Official Gazelle.Julien Chouinard, 33854 Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 1231 Quebec, March 18, 1970.Present: The Lieutenant-Governor in Council CONCERNING the extension of the right t» levy of the trucking Rarity Committee for tin-Montreal Region.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour and Manpower: That the right to levy of the Trucking I'arily Committee for the Montreal Region, authorized by n by-law approved by Order in Council number 715 of March 19, 1969, be extended until May 31, 1970, at the same rates and on the same conditions.Julien Chouinard, 33856-0 Clerk of thc Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 1232 Québec, March 18, 1970.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the extension of the right to levy of the Comité paritaire de VAlimentation île Chicoutimi.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour anil Manpower: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 2003 Que le droit de prélèvement du Comité puri-tairc de l'Alimentation de Chicoutimi, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1811 du 21 juin 1968, soit prolongé jusqu'au 31 mai 1970, aux mêmes taux ct conditions.Le greffier du Conseil exécutif, 33856-0 Julien Ciiouinaiid.That the right to levy of the Comité paritaire de l'Alimentation dé Chicoutimi, authorized by a bylaw approved by Order in Council number 1811 of June 21, 1968, be extended until May 31, 1970, at thc same rates and on the same conditions.Julien Chouinard, 33856-q Clerk of the Executive Council.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1233 Québec, lc 18 mars 1970.Présent: I.c Lieutenant-gouverneur en conseil.concernant la prolongation du droit de prélèvement du Comité conjoint des matériaux de const ruction (Fer & Bronze d'Ornementation).ii.est ordonné, sur la proposition de l'hono-rnlile ministre du Travail et de la Main-d'œuvre: Que le droit de prélèvement du Comité conjoint des matériaux dc construction (Fer & Bronze d'Ornementation), autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 719 du 19 mars 1969, soit prolongé jusqu'nu 31 moi 1970.aux mêmes taux et conditions.Le greffier du Conseil exécutif, 33S50-O Juuen Chouinard.Order in Council Executive Council Chamber Number 1233 Québec, March 18, 1970.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the extension of the right to levy of the Building Materials Joint Committee (Ornamental Iron & Bronze).It is ordered, upon thc recommendation of the Honourable Minister of labour and Man-|)ower: That the right to levy of thc Building Materials Joint Committee (Ornamental Iron & Bronze), authorized by a by-law approved by Order in Council number 719 of March 19, 1969, be extended until May 31, 1970, at the same rates and on the same conditions.Julien Chouinard, 33856-q Clerk of the Executive Council.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1234 Québec, le 18 mars 1970.Présent: Lc Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation du droit de prélèvement du Comité paritaire de l'Industrie de l'Automobile de Montréal et du district Il kst ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail et de la Main-d'œuvre: Que le droit dc prélèvement du Comité paritaire de l'Industrie de l'Automobile de Montréal et du district, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 232 du 29 janvier 1969, soit prolongé jusqu'au 31 mai 1970, aux mêmes taux ct conditions.Le greffier du Conseil exécutif, 33856-0 Julien Chouinard.Order in Council Executive Council Chamber Number 1234 Québec, March 18, 1970.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the extension of the right to levy of the Parity Committee for the Automobile Industry of M out real and District It is ordered, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour and Manpower: That thc right to levy of thc Parity Committee for the Automobile Industry of Montreal and District, authorized by a by-law approved by Order in Council number 232 of January 29, 1969, be extended until May 31, 1970, at the same rates and on the same conditions.Julien Chouinard, 33s56-0 Clerk of thc Executive Council.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1235 Québec, lc 18 mars 1970.Présent; Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation du décret relatif un Commerce de l'Alimentation dc Jonquière.Il kst ordonné, sur la proposition dc l'honorable ministre du Travail et dc la Main-d'œuvre: Que, conformément aux dispositions dc la Loi des décrets de convention collective (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 143), lc décret numéro 1158 du 19 juillet 1962, relatif au Commerce de l'Alimentation de Jonquière, soit prolongé jusqu'au 30 juin 1970.Le greffier du Conseil exécutif, 338ôG-o Julien Chouinard.Order in Council Executive Council Chamber Number 1235 Québec, March 18, 1970.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the extension of the decree respecting the Food Trade of Jonquière.It is ordered upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour and Manpower: That, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (BSQ 1964, c.143), Decree number 1158 of July 19, 1962, respecting the Food Trade of Jonquière be extended until June 30, 1970.Julien Chouinard, 33856-0 Clerk of the Executive Council. 2004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 18 Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1236 Québec, le 18 mars 1970.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation du décret relatif au Commerce de l'Alimentation au détail de la région de Chicoutimi.Il, est ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 143), le décret numéro 1574 du 14 juin 1967 et modifications, relatif au Commerce de l'Alimentation au détail de la région de Chicoutimi, soit prolongé jusqu'au 30 juin 1970.Le greffier du Conseil exécutif, 33856-0 Julien Chouinard.Order in Council Executive Council Chamber Number 1236 Québec, March 18, 1970.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the extension of the Decree respecting the Retail Food Trade of the Chicoutimi region.It is ordered upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour and Manpower: That, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.143), Decree number 1574 of June 14, 1967 and amendments, respecting the Retail Food Trade of the Chicoutimi Region, be extended until .Line 30, 1970.Julien Chouinard, 33856-0 Clerk of the Executive Council.Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre Avis de modification Industrie des vêlements d'hommes et de garçons Lc ministre du Travail ct de la Main-d'œuvre, l'honorable Jean Cournoyer, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions dc la Loi des décrets dc convention collective (S.R.Q.1964, chapitre 143), qu'à la suite d'une requête de parties contractantes au décret numéro 711 du 30 avril 1963 et modifications, relatif à l'industrie de la confection pour hommes ct garçons dans la province de Québec, les modifications suivantes seront apportées à l'énuméra-tion des parties contractantes: 1° « The Odd Pants Manufacturers Association of Québec » sera radiée comme partie contractante de seconde part.2° « The Québec Council of Odd Pants Employers » sera ajouté comme partie contractante de seconde part.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendements.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, l'honorable ministre du Travail et de la Main-d'œuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Robert Sauvé.Ministère du Travail et de la Main-d'œuvre, Québec, le 28 mars 1970.33856-0 Avis de modification Le ministre du Travail et de la Main-d'œuvre, l'honorable Jean Cournoyer, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 101 du 31 janvier 1957 et modifications, relatif à la fabrication des Department of Labour and Manpower Notice of Amendment Men's and Boys' Clothing Industry Pursuant to the provisions of thc Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q.1964, chapter 143), the Honourable Jean Cournoyer, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that following the filing of a petition by contracting parties to Decree number 711 of April 30, 1963 as amended, respecting the Men's and Boys' Clothing Industry in the Province of Québec, the enumeration of the contracting parties will be amended as follows: 1.\"The Odd Punts Manufacturers' Association of Québec\" will be stricken out as contracting partv of thc second port.2.\"The Québec Council of Odd Pants Employers\" will be added as contracting party of the second part.Publication of this notice docs not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can be made binding only by an order in council that cannot come into force before the date of its publication in the Québec Official Gazelle.During thc thirty days following publication of this notice in the Québec Official Gazelle, the Honourable Minister of Labour and Manpower will consider objections which interested parties may wish to make.Robert Sauve.Deputy Minister.Department of Labour and Manpower, Québec, March 28, 1970.33&>6-0 Notice of Amendment Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.143).the Honourable Jean Cournoyer, Minister of l.uhour and Manpower, hereby gives notice that thc contracting parties to the collective labour agreement respecting the Manufacturing of Caskets in the Province of Québec, rendered obligatory by Decree number 101 of January 31, 19\"» and QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 2005 cercueils dans lc Québec, lui ont présenté une requéle n l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret: 1° Lc paragraphe « a » dc l'article III sera remplacé par le suivant: « III.Taux minimaux de salaires: a) Les taux minimaux de salaires des salariés, y compris les salariés du sexe féminin, travaillant à la fabrication des cercueils, définie dans le champ d'application industriel du présent Décret, dc même que ceux des chauffeurs de chaudières, des gardiens chauffeurs de chaudières, des conducteurs «le machines fixes, des gardiens, des préposés ù l'expédition, des préposés au transport, à l'entretien ou à la réparation des machines, des immeubles, sont les suivants: '/.one I: Le salaire moyen doit être d'au moins $1.95 l'heure.Pour établir le salaire moyen, on divise le montant global des salaires gagnés par tous les salariés que vise le présent décret, par le chiffre total des heures de travail effectuées.Cependant, il faut exclure du montant global des salaires gagnés les montants versés à titre de majorations pour heures supplémentaires de même que les salaires touchés par les personnes qui occupent un emploi dc contremaître ou un poste supérieur ù celui dc contremaître.Taux Horaires Minimaux k compter de lu date de publication.$1.40 A compter du 1er novembre 1970.1.45 Après un an dc service.1.50 Après deux ans dc service.1.55 1.'.- suluircs minimaux suivants s'appliquent aux chefs-conducteurs dc 4e classe, aux gardiens et aux gardiens-chauffeurs seulement: Première année de service.$1.45 Après un an dc service.1.50 Zone 11: Le salaire moyen doit être d'au moins 81.80 l'heure Pour établir le salaire moyen, on divise le montant global des salaires gugnés par tous les salariés que vise le présent décret, par le chiffre total des heures de travail effectuées.Cependant, il faut exclure du montant global des salaires gagnés les montants versés à titre de majorations pour heures supplémentaires dc même que les salaires touchés par les personnes qui occupent un emploi de contrcmnttre ou un poste supérieur ù celui de contremaître.Taux horaires minimaux A compter de la date de publication.$1.35 A compter du 1er novembre 1970.1.40 Après un an dc service.1.45 Après deux ans de service.1.50 Las salaires minimaux suivants s'appliquent aux clicfs-conductcurs de 4c classe, aux gardiens et aux gardiens-chauffeurs seulement: 1ère année.$1.40 Après un an.1.45» 2° L'article IV sera remplacé par lc suivant: « IN'.Les taux de salaires, tant les taux horaires que les taux aux pièces ou les taux horaires de base d'un système minutes de prime au rendement, ne seront pas réduits à l'occasion de la mise en vigueur du présent décret, sauf dans le cas où des changements technologiques sont survenus.Dans un tel cas, les nouveaux taux de salaires devront être soumis au Comité paritaire pour amendments, have petitioned him to submit certain amendments to the said Decree to the Lieutenant-Governor in Council for consideration and decision: 1.Subsection (a) of section III will be replaced by the following: \"III.Minimum Wage Bales: (a) Minimum wage rates for male and female employees engaged in the manufacturing of caskets, as defined in the industrial jurisdiction of this decree, as well as those of boiler firemen, watchmen-firemen, stationary cngincmcn, watchmen and men whose work is concerned with the shipping, transportation, maintenance or repair of machines and buildings, shall be as follows: Zone I: The average wage rate shall be at least $1.95 an hour.To arrive at the average wage, the total earnings for all employees governed by this decree arc divided by the total hours worked.However, the following arc not included in the total earnings: overtime paid; wages of any person holding a position of foreman or above that of foreman.Minimum hourly rales Prom date of publication.$1.40 From November 1st, 1970.1.45 After 1 year's service.1.50 After 2 years' service.1.55 The following minimum rates apply to chief stationary cngincmcn (4th class), watchmen-firemen nnd watchmen only: First year.$1.45 After 1 year's service.1.50 Zone II: The average wage rute shall be at least $1.80 an hour.To arrive at the average wage, the total earnings of all employees governed by this decree arc divided by the total hours worked.However, the following are not included in the total earnings: overtime paid; wages of any person holding a position of foreman or above that of foreman.Minimum hourly rales From date of publication.$1.35 From November 1, 1970.1.40 After 1 year's service.1.45 After 2 years' service.1 - 50 The following minimum wage rates apply to chief stationary cngincmcn (4th class), watchmen-firemen, and watchmen only: First year.$1,40 After 1 year's service.1.45\" 2.Section IV will be replaced by the following: \"IV.The wage rates, as well as the hourly wage rates, the piece-work rates or the basic hourly wage rates of a standard minutes bonus system shall not be reduced when the present decree comes into force, except when technological changes have occurred.In such event, the new wage rates shall be submitted to the Joint Committee for vcrifien- 2006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 18 vérification ct approbation advenant que lesdits taux soient contestés.La décision du Comité paritaire sera finale ct liera toutes les parties en cause.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendements.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avunt lu date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication dc cet avis clans la Gazelle officielle du Québec, l'honorable ministre du Travail et dc la Main-d'ocuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Robert Sauve.Ministère du Truvail ct dc la Main-d'ocuvre, Québec, le 28 murs 1070.33856-0 tion and npproval should thc said rates lie contested.The derision of the Joint Committee shall be final nnd binding for all parties conccriud.\" Publication of this notice docs not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can be muilc binding only by an order in council that cannot come into force before the date of its publication in the Québec Official Gazelle.During the thirty days following publication of this notice in thc Quebec Official Gazelle, the Honourable Minister of Labour and Manpower will consider objections which interested parties may wish to make.Robert Sauvé, Depuly Minister.Department of labour and Manpower.Québec, March 28, 1970.33356-0 Avis de prélèvement L'honorable Jeun Cournoyer, ministre du Travail et dc la Mnin-d'oeuvre, donne avis par les présentes que lc Comité paritaire des coiffeurs pour hommes dc Montréal, établi en exécution du décret numéro 1790 du 12 octobre 1966 et amendements, a été autorisé par règlement approuvé pur l'arrêté en conseil numéro 1227 du 18 mars 1970, lc tout d'accord avec les dispositions de la Loi des décrets dc convention collective (Statuts refondus dc Québec, 1964, chapitre 143) à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant les conditions ci-après décrites: 1.Cotisai ion La période dc cotisation s'étend du 1er avril 1970 au 31 décembre 1970; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 1790 et nmendements, doivent verser nu Comité pnritnire une somme équivalente à Yi dc 1% dc In liste de paye, salaires, commissions et allocations qu'ils versent ù leurs salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis pur ledit décret numéro 1790 ct amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à \\2 de 1% basée sur une rémunération hebdomadaire moyenne de S100.Tout employeur ou employeur professionnel qui pratique lui-même lc métier visé pur lc décret numéro 1790 est de plus considéré, aux fins du présent règlement, comme un artisan.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 1790 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente ù Yî de 1% de leurs salaires, commissions et allocations.2.Mode de perception En vue de faciliter lu perception de ces cotisations, lc Comité paritaire met ù la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués les noms, prénoms et adresse dc leur salarié, leur qualification, le nombre d'heures de travail, les salaires payés et tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer ct le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.Notice of Levy Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.14:5), the Honourable Jean Cournoyer, Minister of Labour and Mnn|h>wcr, hereby gives notice that the Purity Committee of Men's Hairdressers of Montreal (established in pursuance of decree number 1790 of October 12, 1966, as amended), has been authorized to levy dues on the professional employers, artisans and employees subject to the said decree, according to the conditions mentioned below.A by-law approved by Order in Council number 1227, dated March IS.1971).authorizes such levy.1.Dues The contribution period extends from April I.1970, to December 31, 1970.The levy is carried out as follows: (a) Professional employers governed by Decree number 1790 and amendments shall pay the Parity Committee an amount equivalent lu }¦< of 1% of the salaries, commissions and allowances paiil to their employees who are subject Ip the said decree.(6) Artisans subject to Decree number 1790 and amendments must turn over to the Parity Committee an amount equivalent to 1 \u2022_> of I9c of the average wage which is set at 8101) per week.Any employer or professional employer who himself plies any of the trades concerned i\" Decree number 1790 and amendments is then considered as nn artisan, for the purposes of this by-law.(c) Employees governed by Decree number 1790 and amendments must turn over lo the Parity Committee un amount equivalent to .\u2022_> of 1% of the salary, commissions and allowances received.2.Collection of Dues To facilitate the collection of such dues, the Parity Committee supplies professional employers with report forms on which must be given the family name, given name and address of cadi employee in their service; thc employee's competency, the number of hours worked, salary paid and all other details required by the said Committee.Every month, the professional employer shall complete and sign his report and forward it 1° the Parity Committee. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 2007 L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire dc ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le dixième jour du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel ct dc ses salariés.1/3 Comité a le pouvoir d'exiger l'assermcntation dudit rapport chaque fois qu'il le juge ù propos.Les artisans doivent égulcincut transmettre mensuellement au Comité paritaire, le ou avant le dixième jour du mois suivant la dute d'expirn-tion de In période pour laquelle elles sont exigibles, les cotisations qu'ils sont tenus dc verser audit Comité.I,c prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement nu Comité par l'employeur professionnel, l'artisan ct le salarié, sans mise en demeure nu préalable.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions dc la Loi des décrets de convention collective, lc Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel dc ses opérations financières au ministre du Travail et de la Main-d'ocuvre, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre dc chaque année.Ci-annexé, un état des revenus ct des dépenses probables du Comité paritaire des Coiffeurs pour hommes de Montréal, pour la période comprise entre le 1er avril 1970 et lc 31 décembre 1970.Comité paritaire des Coiffeurs linn Hommes de Montréal Prévisions budgétaires pour la période du 1er avril 1970 au 31 décembre 1970.Sommaire: Comptes dc dépenses administration gé- nérale.822,027 Comptes dc dépenses administration inspecteurs.19,249 Comptes de dépenses membres du Comité.4,171 Comptes de dépenses administration propriété.6,995 Comptes divers.4,475 Total des défenses prévues.$57,517 Retenus: Cotisations patronales.$17,350 Cotisations ouvrières.17,350 Cotisations nrtisannlcs.22,900 Pénalités ct amendes.5,500 Honoraires d'examens.3,700 Berenus de loyer.1,125 Total des revenus prévus.$67,925 Surplus.$10,408 Comptes dépenses administration générale: Salaire du secrétaire gérant.$ 6,120 Salaires administration générale.10,360 At the end of each week and on behalf of the Parity Committee, the professional employer shall collect, by means of a check-off, the levy imposed on his employees.The professional employer sliall forward his monthly report to the Parity Committee on or before the 10th of thc month following the date of expiry of the period for wliich it is required.The professional employer's dues together with those of his employees shall accompany the said report.The Committee has the authority to exact thc attestation of the said report whenever it deems it advisable to do so.Every month, artisans shall also forward the dues puyublc to thc said Parity Committee on or before the 10th of the month following the expiry dutc of the period for which they are required.Thc levy imposed by this by-law is payable monthly to thc said Parity Committee by the professional employer, the artisan and the employee without formal notice beforehand.3.Financial Report In compliance with thc provisions of the Collective Agreement Decrees Act, the Parity Committee snail submit a quarterly financial report to the Minister of Labour on thc following set dates: March 31st, June 30th, September 30th nnd December 31st of each year.An estimate of thc revenue and expenditure of the Parity Committee of Men's Hairdressers of Montreal for the period extending from April 1, 1970, to December 31, 1970, is given below.Parity Committee of Men's Hairdressers of Montreal Estimate of revenue nnd expenditure for the period extending from April 1, 1970, to De- cember 31, 1970.Summary: General udminislrution expenses.$22,627 Inspection administration expenses.19,249 Expenses \u2014 committee members.4,171 Expenses for administration of premises.6,995 Miscellaneous expenses.4,475 Estimated total expenses.$57,517 Retenue: Employers' dues.$17,350 Employees' dues.17,350 Artisans, dues.22,900 Penalties and fines.5,500 Examination fees.3,700 Rent.1,125 Estimated total revenue.$67,925 Estimated surplus.S10.40S General administration expenses: Managing secretary's salary.$ 6,120 Salaries, general administration personnel.10.360 2008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, nb 13 Assurance-chdmage (part du comité).S 188 Assurance collective (part du comité).116 Régime rentes du Québec (part du comité).244 Papeterie.1,700 Téléphone et télégrammes.720 Frais postaux.1,800 Intérêts et frais de banque.225 Abonnement ct publicité.35 Congrès et délégations (secrétaire gérant).66 Publication de décret ct publicité.¦ 395 Assurance gardien des fonds.25 Auditeur.- 600 Commission des accidents du Travail- 33 Total dépenses administration générale prévues.S22.627 Comptes dépenses administration inspecteurs: Salaires des inspecteurs.$11,000 Assurance chômage (part du comité).168 Assurances collectives (part du comité).87 Régime Rentes du Québec (part du comité).187 Allocation automobile.2,295 Frais de vérification.540 Frais judiciaires.3,000 Papeterie.250 Gasoline.1,700 Commission des Accidents du Travail.22 Total dépenses administration inspecteurs prévues.$19,249 Comptes dépenses membres du comité: Assemblées spéciales.$ 1,442 Assemblées régulières jetons de présences.630 Assemblées régulières frais déplacements.1,965 Congrès et délégations.134 Total dépenses membres du comité prévues.$ 4,171 Comptes dépenses administration propriété: Éclairage.$ 360 Chauffage.360 Entretien (matériel seulement).45 Salaire du concierge.600 Taxes municipales et scolaires.2,900 Remboursements d'hypothèques (Cap.etint).2,730 Total dépenses administration propriété prévues.$ 6,995 Comptes divers: Frais d'examens de qualification du travail.$ 4,475 Le sous-ministre, Robkrt Sauvé.Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, Québec, le 28 mars 1970.33856-o Avis de prélèvement L'honorable Jean Cournoyer, ministre du Travail et dc la Main-d'œuvre, donne avis par les présentes que la Commission conjointe des Unemployment Insurance (Committee.s share).,.$ |g Group insurance (Committee's share).ng Québec Pension Plan (Committee's share).244 Stationery.1,700 Telephone and telegrams.720 Postage.:.1,800 Banking, interest and costs.225 Subscription and advertising.35 Conference and delegation expenses (managing secretary).66 Publication of decree and advertising.395 Fidelity bond.25 Auditor's fees.600 Workmen's Compensation Commission.33 Estimated total, general administration expenses.$22,627 Inspection administration expenses: Inspectors'salaries.811,000 Unemployment Insurance (Committee's share).ICS Group insurance (Committee's share).87 Quebec Pension Plan (Committee's share).187 Automobile allowance.2.295 Auditor's fees.540 Legal costs.3,000 Stationery.'.250 Gusolinc.¦.1,700 Workmen's Compensation Commission.22 Estimated total, inspection administration expenses.S 19,249 Expenses \u2014 Committee members: Special meetings.8 1,442 Regular meetings, attendance fees.630 Regular meetings, travelling expenses.1,965 Conferences and delegations.131 Estimated total, expenses \u2014 Committee members).S 4,171 Expenses for administration of premises: Light.8 360 Heating.360 Maintenance (equipment only).45 Janitor's salary.600 Municipal and school taxes.2,900 Reimbursement of mortgage (capital and interest).S 2,730 Estimated total expenses for administration of premises.8 6,995 Miscellaneous expenses: Competency examination expenses.S 4,47* Robert Sauvé, Deputy Minister.Department of Labour and Manpower, Québec, March 28, 1970.33856-0 Notice of Levy Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q.1964.chapter 143), the Honourable Jean Cournoyer, Minister of QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 2009 Coiffeurs pour domes de Montréal, établie en exécution du décret numéro 673 du 30 mars 1965, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1230 du 18 mars 1970, le tout d'accord avec les dispositions de la Loi des décrets de convention collective (Statuts refondus de Québec, 1964, chapitre 143), ù prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant les conditions ci-après décrites: 1.Cotisai ion La période dc cotisation s'étend du 1er avril 1970 au 31 décembre 1970; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 673 ct amendements, doivent verser ù lu Commission conjointe une somme équivalente ù Yi dc 1% dc la liste des salaires fees, commissions, bonis ct allocations qu'ils versent à leurs salariés assujettis audit décret.Ii) Les artisans régis par ledit décret numéro 673 ct amendements, doivent verser ù la Commission conjointe une somme équivalente à Yi de 1% basée sur une rémunération hebdomadaire moyenne dc 860.Tout employeur ou employeur professionnel qui pratique lui-même l'un ou l'autre des métiers visés pur le décret numéro 673 et amendements, est dc plus considéré comme un artisan, aux 6ns du présent règlement.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 673 et amendements, doivent verser à la Commission conjointe une somme équivalente à Yi de 1% dc leurs salaires fixes, commissions, bonis ct allocations.2.Mode de perception En vue de faciliter lo perception de ces cotisations, lu Commission conjointe met A la disposition des employeurs professionnels des formules de rap|k>rt sur lesquelles doivent être indiqués les heures de travail, les salaires payés, y compris la proportion îles commissions gagnées, l'argent perçu au cours dc la semaine ct les sommes versées à la Commission conjointe.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient remplis ct retournés à la Commission conjointe à tous les mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin dc chaque semaine, ù même la rémunération de chacun de ses salariés les sommes qui reviennent à la Commission conjointe et les faire parvenir lui-même à ladite Commission en même temps que sa propre cotisation.Le rapport dc l'employeur professionnel, accompagné des cotisations, doit être signé et transmis à la Commission conjointe dans les dix (10) jours qui suivent l'expiration dc la période pour laquelle il est exigible.La Commission a le pouvoir d'exiger l'asser-mentatinn dudit rapport chaque fois qu'il le juge ù propos.Les artisans doivent également transmettre mensuellement à la Commission conjointe le ou ayant le dixième jour du mois suivant la date d'expirulion de la période pour laquelle elles sont exigibles, les cotisations qu'ils sont tenus de verser à ladite Commission.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et lc salarié, sans mise en demeure au préalable, dans le délai ci-dessus mentionné.Labour and Manpower, hereby gives notice that the Joint Commission of the Ladies' Hairdressing Trade of Montreal (established in pursuance of decree number 673 of March 30, 1965) has been authorized to levy dues on the professional employers, artisans and employees subject to the said decree, according to the conditions mentioned below.A by-law, approved by Order in Council 1230, dated March 18, 1970, authorizes such levy.1.Dues The contributions period extends from April 1, 1970, to December 31, 1970.It is carried out as outlined below: (a) Professional employers governed by said decree number 673 as amended shall turn over to thc Joint Commission an amount equivalent to Yî of 1% of the fixed salaries, commissions, bonuses nnd allowances paid to their employees who arc subject to the said decree.(Ii) Artisans subject to said decree number 673, -hall turn over to the Joint Commission an amount equivalent to \\ $ of 1% of the average weekly salary of S60.Every employer or professional employer wdio himself plies one of the trades covered by decree numlicr 673 os amended is moreover considered as an artisan for the purposes of this by-law.(c) Employees subject to soid decree number 673 as amended must turn over to thc Joint Commission an amount equivalent to Yz of 1% of their fixed salaries, commissions, bonuses and allowances, 2.Collection Method To facilitate thc collection of such dues, thc Joint Commission supplies professional employers with report forms on which thc following information shall l>c inscribed: hours worked: wages paid, including thc proportion of commissions earned: money collected during thc week and amounts turned over to thc Joint Commission.Thc professional employer must sec that these reports be completed nnd forwarded to the Joint Commission, each month.At thc end of each week, by means of a checkoff the professional employer must collect the sums due thc Joint Commission.He must forward them himself to the Joint Commission together with his own dues.The professional employer's report which accompanies thc dues, must be signed and forwarded to thc Joint Commission within the ten (10) days following the expiry of thc period for which it is required.Thc Commission has thc authority to exact a sworn attestation of thc said report whenever it deems it advisable to do so.Every month, artisans must also forward the dues payable to the said Commission on or before thc 10th of the month following the expiry date of thc period for which they arc required.The levy imposed by this by-law is payable monthly by the professional employer, thc employer, the artisnn nnd the employee, without formai notice beforchnnd nnd within the time limit mentioned above. 2010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 18 3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi des décrets de convention collective, la Commission conjointe doit présenter un rapport trimestriel dc ses opérations financières nu Ministre du Travail ct dc In Main-d'oeuvre, nux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque nnnéc.Ci-nnnexé, un état des revenus ct des dépenses prévus de la Commission conjointe des coiffeurs pour dames de Montréal, pour la période comprise entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1970.Commission- conjointe des coiffeurs pour dames de Montréal Prévisions budgétaires pour la période du 1er avril 1970 au 31 décembre 1970.Sommaire: Comptes de dépenses administration générale.-.S 75,100 Comptes dc dépenses administration inspecteurs.51,541 Comptes dc dépenses membres du Comité.____.5,700 Comptes de dépenses administration propriété.9,760 Comptes divers.7,200 Immobilisations à même les revenus.4,225 Total des dépenses prévues.S153.5S6 Retenu»: Cotisations patronales.S 48,825 Cotisations ouvrières.48,825 Cotisations artisanales.13,875 Pénalités ct amendes.14,850 Honoraires d'examens.10,125 Intérêts sur placements comptabilité générale.4,038 Total des revenus prévus.S140.538 Déficit prévu à être comblé par lu réserve.S 13,048 Comptes dépenses administration générale: Salaire du Secrétaire Gérant.S 7,30S Salaires administration générale.39,960 Assurance-chômage (part du comité).524 Assurance collective (part du comité).1,691 Location d'équipement.450 Régime Rentes du Québec (part du comité).803 Papeterie.11,475 Téléphone ct télégrammes.1,800 Frais postaux.1,800 Abonnement et publicité.2,500 Congrès et délégations (secrétaire gérant).150 Publication de Décret ct publicité.3,775 Assurance gardien des-fonds.25 Assurances générales.600 Auditeur.750 Crédit maladie.1,454 Commission des Accidents du Travail.95 Total dépenses administration générale prévues.S 75,160 3.Financial Report In compliance with the provisions of the Collective Agreement Decrees Act, the Joint Commission shall submit a quarterly report of its financial operations to thc Minister of Labour and Manpower on thc following set dates: March 31, June 30, September 30 and December 31 of each year.An estimate of thc revenue and expenditure of the Joint Commission of thc Ladies llniidrcssing Trade of Montreal for thc period extending from April 1, 1970, to December 31, 1970, i- given below.Joint Commission of the I.a : : : : - Hairdiiessixo.Trade of Montreal Estimate of revenue and expenditure for the period extending from April I, 1970, to December 31, 1970.Summary: General administration expenses.S 75,160 Inspection administration expenses.51,541 Expenses, committee members.5,700 Expenses for administration of premises !t.760 Miscellaneous expenses.7,200 Fixed assets paid out of revenue.4.225 Estimated total expenses.$15.3,586 Revenue: Employers'dues.8 IS.S25 Employees' dues.IS.S25 Artisans' dues.I3.N75 Penalties and fines.14.850 Examination fees.10,125 Interest on investments, general accounting.4,03s Estimated total revenue.SI40.53S Estimated deficit to be covered by reserve fund.\u2022$ 13,048 General administration expenses: Managing secretary's salary.\u2022?7,308 Salaries, general administration personnel.;.30,980 Unemployment Insurance (Committee's share).524 Group insurance (Committee's share) 1.601 Equipment rental._.4o0 Québec Pension Plnn (Committee's share).$08 Stationery.I l.4/o Telephone and telegrams.''°JJJ Postage.MS Subscription and advertising.Conference and delegation expenses (mnnnging secretary).1™| Publication of decree and advertising.3,/ / Fidelity bond.rj?General insurance.*5 Auditor's fees.'* Sick leave credits.¦ \u2022 1 \u20224?î Workmen's Compensation Commission Estimated total, general administration expenses.S ,0,lw QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 2011 Comptes dépenses administration inspecteurs: Salaires des inspecteurs.S 36,640 Assurance chômage (part du comité).368 Assurances collectives (part du comité) 1,138 Régime Rentes du Québec (part du comité)._.611 Allocation automobile.3,200 Frais de vérification.1,400 Frais judiciaires.7,010 Crédit maladie-.1,100 Commission des Accidents du Travail.74 Total of 1% of their payroll for the employees subject to the said decree.(b) Artisans governed by said Decree number 643 and amendments shall turn over to the Parity Committee an amount equivalent to y, of 1% of their average wage of $100 a week.(c) Employees governed by said Decree number 643 and amendments shall turn over to the Parity Committee an amount equivalent to j/2 of 1% of their wages.2.Collection of Dues To facilitate the collection of such dues, the Purity Committee supplies professional employers with report forms on which all the information required by thc Parity Committee shall be given.Every month, the professional employer shall complete, sign and forward his report to the Parity Committee.At thc end of each week nnd on behalf of the Purity Committee, the professional employer must collect this levy by means of n check-off.Thc professional employer shall forward his monthly report to the Parity Committee on or before thc 10th of the month following the onr for which it is required.Thc professional employer's dues together with those of his employé» shall accompany thc said report.The Committer has the authority to exact a sworn attestation of the said rejMirt whenever it deems it advisable lo do so.Thc levy imposed by this by-law is payable monthly to the said Parity Committee by the professional employer, the artisan and the employee, without formal notice beforehand.Should a professional employer or an artisan refuse to pay his dues or give necessary information, he will be given five (5) days' notice to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial Report In compliance with the provisions of t he Collective Agreement Decrees Act, the Parity Committee shall submit a quarterly financial report to the Minister of Labour and Manpower, on the following set dates: March 31st, June 30th, September 30th nnd December 31st of each year.An estimate of receipts and disbursements of the Retail Fur Trade Joint Committee of Montreal and district for the period extending from April 1, 1970, to December 31, 1970.is given below.Retail Fur Trade Joint Committee or Montreal and district Estimate of revenue and expenditure for the period extending from April 1, 1970.to December 31, 1970.Summary: General administration expenses.S 5,390 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 2013 Comptes de dépenses administration inspecteurs.$ 7,586 Comptes de dépenses membres du Comité.1-860 Comptes de dépenses administration rnriété.720 propi Inspection administration expenses.$ 7,586 Expenses \u2014 committee members.1,860 Expenses for administration of premises.720 Total des dépenses prévues.$15,556 Estimated total expenses.$15,556 Keren us: Cotisations patronales.$ 6,200 Cotisations ouvrières.6,200 Cotisations artisanales.3,200 Pénalités ct amendes.267 Intérêts sur placements comptabilité générale.160 Revenus: Employers* dues.$ 6,200 Employees' dues.6,200 Artisans' ducs.3,200 Penalties and fines.267 Interest on investments \u2014 general accounting.160 Total des revenus prévus.$16,027 Surplus prévu.Estimated total revenue.$16,027 $ 471 Estimated surplus.Comtes dépenses administration générale: Salaire du Secrétaire Gérant.$ 2,811 Salaires administration générale.1,347 Assurance collective (part du comité).94 Papeterie.270 Téléphone ct télégrammes.275 frais postaux.160 Intérêts et frais dc banque.100 Congrès ct délégations (secrétaire gérant) 50 Assurance gardien des fonds.20 Auditeur.255 Commission des Accidents du Travail.8 Total dépenses administration générulc prévues.$ 5,390 Complet dépenses administrai ion insjiecleurs: Salaires des insi>ccteurs.$ 5,916 Assurance chômuge (part du comité).58 Assurances collectives (part du comité).66 Régime Rentes du Québec (part du comité).84 Allocation automobile.1,350 Frais judiciuircs.'.100 Commission des Accidents du Travail.'.12 Total dépenses administration inspecteurs prévues.$ 7,586 Comptes dépenses membres du comité: Assemblées spéciales.S 320 Assemblées régulières jetons dc présences.360 Assemblées régulières frais déplacements 1,080 Congrès ct délégations.100 Total dépenses membres du comité prévues.$ 1,860 Comptes dépenses administration propriété: Loyer.$ 720 Total dépenses administration propriété prévues.s $ 471 General administration expenses: Managing secretary's salary.$ 2,811 Salaries, general administration personnel.1,347 Group insurance (Committee's share).94 Stationery.270 Telephone and telegrams.275 Postage.160 Ranking, interest nnd costs.100 Conference and delegation expenses (managing secretary).50 Fidelity bond.20 Auditor's fees.255 Workmen's Compensation Commission.8 Estimated total, general administration expenses.$ 5,390 Inspection administration expenses: Inspectors' sularics.$ 5,916 Unemployment Insurance (Committee's share).58 Group insurance (Committee's share).66 Québec Pension Plan (Committee's share).84 Automobile allowance.1,350 Legal costs.100 Workmen's Compensation Commission.12 Estimntcd total, inspection administration expenses.$ 7,586 Expenses \u2014 committee members: Special meetings.$ 320 Regular meetings, attendance fees.360 Regular meetings, travelling expenses.1,080 Conferences and delegations.100 Estimated total, expenses \u2014 committee members.$ 1,860 Expenses for administration of premises: Rent.8 720 720 Estimated total, expenses for administration of premises.$ 720 Ae sous-ministre, Robert Sauvé.Robert Sauvé, Deputy Minister.Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, Department of Labour and Manpower, Québec, le 28 mars 1970.33856-o Québec, March 28, 1970.33856-0 2014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' aimée, n° 18 Avis de prélèvement L'honorable Jean Cournoyer, ministre du Travail et de la Main-d'œuvre, donne avis par les présentes que lc Comité conjoint dc la Chapellerie pour (lames ct enfants dans la province de Québec, établi en exécution du décret numéro 142 du 22 janvier 1947 ct amendements, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1225 du 18 mars 1970, le tout d'accord avec les dispositions dc la Loi des décrets dc convention collective (S.R.Q.1964, chapitre 143), à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret, suivant les conditions ci-après décrites: 1.Cotisai ion La période de cotisation s'étend du 1er avril 1970 au 31 décembre 1970; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 142 et amendements, doivent verser au Comité Conjoint une somme équivalente ù % de 1% des salaires fixes ct des pourcentages payés à leurs salariés.b) Les salariés régis par ledit décret numéro 142 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à \\'i de 1% des salaires fixes et pourcentages qui leur sont versés.2.Mode de perception En vue dc faciliter la perception de ces cotisations, lc Comité conjoint met à la disposition des employeurs professionnels des formules de-rapport indiquant les heures de travail, l'argent perçu au cours de la semaine ct les sommes versées au Comité conjoint.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces formules soient remplies et retournées au Comité conjoint à tous les mois.Le rapport dc chaque employeur professionnel doit être signé avant d'être adressé au Comité conjoint.Ce Comité a lc pouvoir d'exiger l'asscr-incntation dudit rapport chaque fois qu'il lc juge ù propos.Lc rapport accompagné des cotisations doit être adressé au Comité conjoint le ou avant lc 10 du mois suivant celui pour lequel il est exigible.Lc Comité conjoint sur réception de ce rapport devra en faire la vérification devra débiter ou créditer selon lc cas, lc compte dc lu partie intéressée.3.Rapport, financier D'accord avec les dispositions dc la Loi des décrets de convention collective, lc Comité conjoint doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail et dc la Main-d'œuvre, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre dc chaque année.Ci-annexé, un état des revenus et des dépenses prévus du Comité conjoint de la Chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec, pour la période comprise entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1970.Le Comité conjoint de la Chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec Prévisions budgétaires pour la période du 1er avril 1970 au 31 décembre 1970.Notice of Levy Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.143) the Honourable Jean Cournoyer, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice tliat Llic Joint Committee of thc Millinery and Women's and Children's Hcadwear Industry for t|lc Province of Québec (established in pursuance of decree number 142 of January 22, 1947 and amendments), has been authorized to levy dues on the professional employers and employees subject to said decree, according to the following conditions.A by-law, approved by Order in Council number 1225, dated March 18, 1970, authorizes such levy.1.Dues Thc contribution period extends from April 1, 1970 to December 31, 1970.The levy is carried out as follows: (a) Professional employers governed by Decree number 142 and amendmenLs shall pay the Parity Committee an amount equivalent to \\\\ of 1% of rcgulur wuges and commissions paid their employees.(b) Employees governed by Decree number 142 and amendments shall turn over to the Parity Committee an amount équivalent lo }i of 1% of their regular salary nnd commissions, 2.Collection of Dues To facilitate thc collection of such dues.lb-Parity Committee supplies professional employers with report forms indicating the hours worked, the money collected during the week and the sums paid to the Parity Committee.Every month, the professional employer must sec that these forms be signed and forwarded to the Purity Committee.Each professional employer's report shall lie signed before being forwarded to the Parity Committee This Committee bus the authority to request a sworn attestation of said report whenever it deems it advisable to do so.Thc report, together with thc contribution shall be forwarded to the Purity Committee on or before the 10th of thc month following the one for which it is required.Upon receiving thc report, the Parity Committee shall check it and debit or credit the interested party's account accordingly.3.Financial Report In compliance with the provisions of the Collective Agreement Decrees Act, the Parity Committee shall submit a quarterly financial report to the Minister of Labour and Manpower on the following set dûtes: March 31st.June 30th, September 30th and December 31st of each year.An estimate of receipts and disburscmenb for the Joint Committee of the Millinery and Women's and Children's Hcadwear Industry for the Province of Québec, for the period extending from April 1, 1970, to December 31, 1970, is given below.Joint Committee of the Millinery and Women's and Children's Headwear I di'stbï for the Province of Queiim Estimate of Revenue and expenditure for the period extending from April 1,1970, to December 31, 1970. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 2015 Sommaire: Comptes de dépenses administration générale.$ 8,111 Comptes de dépenses administration inspecteurs.5,677 Comptes de dépenses membres du Comité.1,100 Comptes dc dépenses administration propriété.4,385 Immobilisations à même les revenus , .700 Total des dépenses prévues.519,973 Retenu*: Cotisations patronales.$ 8,200 Cotisations ouvrières.8,200 Revenus de loyer.2,537 Intérêts sur placements comptabilité gé- ralc.355 Divers.700 Total des revenus prévus.$19,992 Surplus prévu.$ 19 Complex dépense* administration générale: Salaire du Secrétaire Gérant.$ 3,618 Salaires administration générale.2.880 Assurance-chômage (part du comité).65 Assurance collective (part du comité) .103 Papeterie.150 Téléphone ct télégrammes.205 Frais îwsleaux.205 Intérêts ct frais dc banque.KO Abonnement ct publicité.10 ( longrès ct délégations (secrétaire gérant) 50 Assurance gardien des fonds.10 Assura nées générales.200 Auditeur.375 Dépenses générales.MM) Total dépenses administration générale S 8,111 Complex dépcnxcx administration inspecteurs: Salaires des inspecteurs.S 3,600 Assurance chômage (purt du comité).6-1 Assurances collectives (part du comité).163 Caisse dc retraite (part du comité) .150 Allocation automobile.900 Frais judiciaires.100 Gasoline.700 Total dépenses administration inspecteurs prévues.$ 5,677 Comptes dépenses membres du comité: Assemblées spéciales.$ 300 Assemblées régulières jetons de présences 200 Assemblées régulières frais déplacements 600 Total dépenses membres du comité prévues.$ 1,100 Comptes dépenses administration propriété: Loyer.$ 4,385 Summary: General administration expenses.$ 8,111 Inspection administration expenses .5,677 Expenses \u2014 committee members.1,100 Expenses for administration of premises 4,385 Fixed assets paid out of revenue.700 Estimated total expenses.$19,973 Retenue: Employers' dues.$ 8,200 Employees' dues.8,200 Rent.2,537 Interest on investments\u2014general accounting .355 Miscellaneous.700 Estimated total revenue.$19,992 Estimated surplus.$ 19 General administrai ion expenses: Managing secretary's salary.$ 3,618 Salaries, general administration personnel.2,880 Unemployment Insurance (Committee's share).65 (iroup insurance (Committee's share).163 Stationery.150 Telephone and telegrams.205 Postage.205 Banking, interest and costs.80 Subscription und advertising.10 Conference and delegation expenses (managing secretary).50 Fidelity bond.10 General insurance.200 Auditor's fees.375 General expenses.100 Estimated total, general administration expenses.$ 8,111 Inspection adminixlralion expenses: Inspectors' salaries.$ 3,600 Unemployment Insurance (Committee's share).64 Group insurance (Committee's share) .163 Retirement pension fund (Committee's share).,.150 Automobile allowance.900 Legal costs.100 Gasoline.700 Estimated total, inspection administration expenses.$ 5,677 Expenses \u2014 Committee members: Special meetings.$ 300 Regular meetings, attendance fees.2(H) Regular meetings, travelling expenses.(MM) Estimated totul, expenses\u2014Committee members.$ 1,100 Expenses for administration of premises: Rent.$ 4,385 201G GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 88 mars 1970, 108' année, n° 18 Total dépenses administration propriété vues.$ 4,385 Immobilisai ions à même les retenus: Équipements dc bureau.$ 700 Total immobilisations à môme les revenus prévues.$ 700 Le sous-minislre, Robert Sauvé.Ministère du Travail et de lu Main-d'œuvre, Québec, le 28 mars 1970.33856-o Estimated total, expenses for administration of premises.$ 4355 Fixed assets paid out of revenue: Office equipment.% 7qq Estimated total, fixed assets paid out of revenue.$ 703 Robert Sauvé, Deputy Minister.Department of Lain m r and Manpower, Québec, March 28, 1970.338564 Avis de prclèvcinenl L'honorable .lean Cournoyer, ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, donne avis par les présentes (pic le Comité paritaire de l'Horlogerie de Montréal, établi en exécution du décret numéro 586 du 23 mars 1965, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1224 du 18 murs 1970, le tout conformément aux dispositions dc la Loi des décrets dc convention collective (Statuts refondus de Québec 1964, chapitre 143), ù prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisuns et des salariés régis pur ledit décret, suivant les conditions ci-après décrites: Notice of Levy Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, e.143), thc Honourable Jean Cournoyer, Minister ol Labour and Manpower, hereby gives notice tliat the Watchmakers' Joint Committee of Montreal (established in pursuance of Decree number 586 of March 23, 1965) has been authorized to levy dues on the professional employers, artisan! and employees subject to the said decree, according to the conditions outlined below.A bylaw, approved by Order in Council number 1224, dated March 18, 1970, authorizes such levy.1.Cotisation Lu période de cotisation s'étend du 1er avri' 1970 au 31 décembre 1970; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 586, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente ù dc 1% dc leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret (salaires fixes, pourcentages, allocations, commissions, ou bonis payés).b) Les artisans régis pur ledit décret numéro 586, doivent verser au Comité paritaire une .somme équivalente ù \\'> de 1% du saluire hebdomadaire établi sur la buse dc $100 pur semaine.c) Les saluriés régis par ledit décret numéro 586, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à }\u2022> de 1% de leur rémunération (saluircs fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).1.Dues Thc contribution period extends from April 1, 1970, to December 31, 1970.The levy is carried out as follows: (a) Professional employers governed by said Decree number 586 must pay the Parity Committee an amount equivalent to ¥> of \\°/t of their payroll for the employees subject to the said decree (fixed salaries, percentages, allowances, commissions or bonuses paid).(6) Artisans governed by said Decree number 586 must turn over to the Parity Committee an amount equivalent to J/jj of 1% of 11 weekly salary set on the bnsis of $100 )>cr week.(c) Employees governed by said Decree number 586 must turn over to the Parity Committee an amount equivalent to Y> of 1% of their wages (fixed salaries, percentages, allowances, commissions or bonuses).2.Mode de perception Yin vue de faciliter la perception dc ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules dc rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer ct le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin dc chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur lc saluire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant lc 15 du mois suivant la date d'expiration dc la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompugné de la cotisation de l'employeur professionnel et de celles de ses salariés.Lc Comité a le pouvoir d'exiger l'asser-¦nentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge ù propos.2.Collection of Dues To facilitate thc collection of such ducs, 11\"' Parity Committee supplies professional employers with report forms 011 which nlMhe information required by the said Purity Committee must be given.Every month, the professional employer shall complete, sign and forward his report to the Parity Commit Ice.At the end of each week and on the Committee's behalf, the professional employer must collect such levy by means of a check-on\".The professional employer must forward his monthly report to the Parity Commit lee on or before the 15th of the month following the expiry date of the period for which it is required, lue professional employer's dues together with those of his employees must accompany the report.The Committee has the authority to exact u sworn attestation of the said report\" whenever it deems it advisable to do so. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.IS 2017 Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi des décrets dc convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel dc ses opérations financières au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.Ci-anncxé, un état des revenus et des dépenses prévus du Comité paritaire de l'Horlogerie de Montréal, pour la période comprise entre le 1er avril 1970 ct le 31 décembre 1970.Comité paritaire de l'Horlogerie de Montréal Prévisions budgétaires pour la période du Ici-avril 1970 au 31 décembre 1970.Sommaire: Comptes dc dépenses administration générale.$ 4,025 Comptes de dépenses administration inspecteurs.6,889 Comptes de dépenses membres du Comité.____.800 Comptes dc dépenses administration propriété.720 Total des dépenses prévues.$13,034 Retenut: Cotisations patronales.$ 3,500 Cotisations ouvrières.3,500 Cotisations artisanales.5,400 Pénalités et amendes.200 Total des revenus prévus.$12,600 Déficit prévu.$ 434 Comités dépenses administration générale: Salaire du Secrétaire Gérant.$ 2,250 Salaires administration générale.1,405 Papeterie.140 Téléphone ct télégrammes.240 Frais |M>staux.200 Intérêts ct frais dc banque.12 Congrès et délégations (secrétaire gérant) 50 Assurance gardien des fonds.20 Auditeur.300 Commission des Accidents du Travail.8 Total dépenses administration générale prévues.$ 4,625 Comptes dépenses administration inspecteurs: Salaires des inspecteurs.8 5,125 Assurance chômage (part du comité).5.8 Régime Rentes du Québec (part du comité).84 Allocation automobile-:.1,460 Frais judiciaires.150 Commission des Accidents du Travail.12 The levy imposed by this by-law is payable monthly by the professional employer, the artisan and the employee, without formal notice beforehand.3.Financial Report In compliance with thc provisions of the Collective Agreement Decrees Act, thc Parity Committee shall submit a quarterly financial report to the Minister of Labour and Manpower on the following set dates: March 31st, June 30th, September 30th and December 31st of every year.An estimate of receipts and disbursements of the Watchmakers' Joint Committee of Montreal for the period extending from April 1, 1970, to December 31, 1970, is given below.Watchmaker's Joint Committee of Montreal Estimate of revenue and expenditure for thc period extending from April 1,1970, to December 31, 1970.Summary: General administration expenses.$ 4,625 Inspection administration expenses.6,889 Expenses \u2014 committee members.800 Expenses for administration of premises 720 Estimated total expenses.$13,034 Revenue: Employers'dues.$3,500 Employees' dues.3,500 Artisans' dues.5,400 Penalties and fines.200 Estimated total revenue.812,600 Estimated deficit.$ 434 General administration expenses: Managing secretary's salary.8 2,250 Salaries, general administration i>erson- nel.1,405 Stationery.140 Telephone and telegrams.240 Postage.200 Hanking, interest and costs.12 Conference ami delegation expenses (managing secretary).50 Fidelity bond.20 Auditor's fees.300 Workmen's Comix-nsation Commission.8 Estimated total, general administration expenses.S 4,625 Inspection administration expenses: Inspectors' snlurics._.S 5,125 Unemployment Insurance (Committee's share).58 Québec Pension Plan (Committee's share).84 Automobile allowance.1,460 Legal costs.Workmen's Compensation Commission.12 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 13 2018 Total dépenses administration inspecteurs prévues.8 6,889 Comptes dépenses membres du comité: Assemblées régulières jetons de présences $ 200 Assemblées régulières frais déplacements 600 Total dépenses membres du comité prévues.$ 800 Comptes dépenses administration propriété: Loyer.$ 720 Total dépenses administration propriété prévues.8 720 Le sous-minislre, Robert Sauvé.Ministère du Travail et de lu Main-d'ocuvre, Québec, le 28 mars 1970.33856-0 Estimated total, inspection administration expenses.$ 6,889 Expenses \u2014 Committee members: Regular meetings, attendance fees.$ 200 Regular meetings, travelling expenses.600 Estimated total, expenses \u2014 Committee members.$ jqq Expenses for administration of premises: Rent.$ 720 Estimated total, expenses for administration of premises.S 720 Robert Sauve, Deputy M mister.Department of Labour and Manpower, Québec, March 28, 1970.338864 Avis de prélèvement L'honorable Jean Cournoyer, ministre du Travail ct «le la Main-d'ocuvre, donne avis par les présentes que le Comité conjoint de l'industrie dc la construction dc Québec, établi en exécution (lu décret numéro 3127 du 22 octobre 1969, u été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1229 du 18 mars 1970, le tout conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (Statuts refondus dc Québec 1904, chapitre 143), ù prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés régis par ledit décret suivant lu méthode ct le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend dc la dutc de publication du présent règlement dans la Gazelle officielle du Québec jusqu'au 30 avril 1970; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Tous les employeurs professionnels de l'Industrie de la Construction assujettis au décret numéro 3127, doivent verser au Comité Conjoint une somme équivalente à Yi dc 1% de la liste des suluircs, bonis, vuennecs ou allocations qu'ils versent il leurs salariés régis par ledit décret, sauf les gérants, surintendants ct employés dc bureau.h) Tous les salariés régis par ledit décret numéro 3127, doivent verser au Comité Conjoint une cotisation équivalente ù Yi de 1% de leurs .salaires, bonis, vacances ou allocations, sauf les gérants, surintendants ct employés de bureau.2.Mode de perception Tous les employeurs professionnels de l'Industrie dc la Construction régis par le décret numéro 3127 doivent percevoir pour lc Comité Conjoint, les cotisations imposées aux salariés à même le saluire, bonis, vacances ou allocations qu'ils sont tenus de payer ù ceux-ci.Les employeurs professionnels régis pnr ledit décret doivent transmettre au Comité Conjoint un rapport mensuel accompagné de leurs propres cotisations et des sommes perçues de leurs salariés sur les formules fournies par le Comité Conjoint à cet effet; ce rapport doit être transmis au Comité Conjoint au plus tard le 15 du mois suivant pour lequel il est exigible.Mot ice of Levy Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, chapter 143), the Honourable Jean Cournoyer, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that the Joint Committee of the Construction industry, Quebec (established in pursuance of decree iiumlxr 3127 of October 22, 1969) has been authorized to levy dues on the professional employers and employees subject to said decree, according to thc method and rate hereof 1er described.A by-law, approved by Order in Council number 1229, dated March 18, 1970, authorizes this levy.1.Dues The contribution period extends from the dutc of thc publication of this by-law in the Québec Official Gazelle until April 30.1970.It is carried out as outlined below: (a) All professional employers of the Construction industry, subject to decree number 3127, must turn over to the Joint Committer an amount equivalent to Yi of 1% of the salaries, bonuses, vacations and allowances paid to their employees governed by said decree, except for managers, superintendents and office personnel.(6) All employees governed by said decree 3127, except for managers, superintendents and office personnel, must turn over to the Joint Committee, dues equivalent to Yz of 1% ot I heir salaries, bonuses, vacations and allowance*.2.Collection of Dues All professional employers of the Construction industry governed by thc said decree number 3127 must collect from thc salaries, bonuses, vacations or allowances paid and on the Joint Committee's l>ehalf, the dues levied upon the employees.Professional employers governed by said decree must supply thc Joint Committee with a monthly report accompanied by their own dins and the sums collected from their employees, 'llus report, written on special forms supplied by tlir Joint Committee, must be forwarded to the Joint Committee at least by thc 15th of the month following that for which it is required. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 Pour les fins des articles 1 et 2 du présent règlement (cotisation et mode de perception), toute personne à laquelle est confié du travail à forfait ou n la pièce est un salarié si elle ne fournit pas les matériaux.Celui qui confie tel travail est pour les mêmes fins son employeur et aussi l'employeur de tous les autres ouvriers embauchés par elle.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions dc la Loi des décrets dc convention collective, le Comité Conjoint iloit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au ministre du Travail et de la Main-d'ocuvre, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.Ci-annexé, un état des revenus et des dépenses probables du Comité Conjoint de l'Industrie de la Construction dc Québec, pour la période se terminant le 30 avril 1970.Comité Conjoint de l'Industrie de la constiiuction de québec Prévisions budgétaires pour la période «lu 1er mars 1970 au 30 avril 1970.Sommaire: Comptes dc dépenses administration générale.:.$ 29,344 Comptes dc dépenses administration inspecteurs._.58,430 Comptes administration sécurité sociale 1,753 Comptes de dépenses membres du Comité.2,400 Comptes de dépenses administration propriété.8,522 Comptes divers.6,850 Total des dépenses prévues.$107,299 Retenus: Cotisations patronales.$ 40,000 Cotisations ouvrières.40,000 Pénalités et amendes.3,000 Honoraires d'examens.600 Revenus dc loyer.1,460 Intérêts sur placements vacances.4,000 Intérêts sur placements comptabilité générale.3,800 Divers.6,250 Total des revenus prévus.$ 99,110 Déficit prévu.$ 8,189 Comptes dépenses administration générale: Salaire du Secrétaire Gérant.$ 2,832 Salaires administration générale.19,755 Assurance-chômage (part du comité).94 Assurance collective (part du comité) 325 Location d'équipement.1,713 Régime Rentes du Québec (part du comité).196 Papeterie.300 Téléphone et télégrammes.560 Frais postaux.600 Intérêts ct frais de banque.60 Abonnement et publicité.60 Publication de Décret et publicité____ 2,400 2019 For the purposes of sections 1 and 2 of this by-law (dues and collection of dues), anyone who performs contract or piece work is an employee provided that he does not furnish the materials.Similarly, for the same purposes, the person who gives out the work is considered as this employee's employer and that of any other worker hired by said employee.3.Financial Report In compliance with the Collective Agreement Decrees Act, the Joint Committee must submit a quarterly financial report to the Minister of Labour and Manpower on the following set dates: March 31, June 30, September 30 nnd December 31 of each year.Attached herewith is an estimate of revenue and expenditure of thc Joint Committee of thc Construction Industry of Québec, for thc period ending on thc 30th of April 1970.Joint Committee op the Construction Industry op Québec Estimate of revenue and ex]>enditiirc for thc period extending from March 1, 1970, to April 30, 1970.Summary: General administration expenses.$ 29,344 Ins|>ection administration expenses.58,430 Social security administration expenses 1,753 Expenses, committee members.2,400 Expenses for administration of premises 8,522 Miscellaneous expenses.6,850 Estimated total expenses.$107,299 Revenue: Employers'dues.$ 40,000 Employees' dues.40,000 Penalties and fines.3,000 Examination fees.600 Rent.1,460 Interest on vacation pay invested.4,000 Interest on investments, general accounting .3,800 Miscellaneous.6,250 Estimated total revenue.$99,110 Estimated deficit.$ 8,189 General administration expenses: Managing secretary's salary.$ 2,832 Salaries, general administration personnel.19,755 Unemployment Insurance (Committee's share).94 Group insurance (Committee's share) 325 Equipment rental.1,713 Québec Pension Plan (Committee's share).190 Stationery.300 Telephone and telegrams.560 Postage.600 Banking, interest and costs.60 Subscription and advertising.60 Publication of decree and advertising.2,400 2020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1070, 102' année, n° 13 Auditeur.S 400 Commission des Accidents du Travail 49 Total dépenses administration générale prévues.8 29,344 Comptes dépenses administration inspecteurs: Salaires des inspecteurs.8 37,935 Assurance chômage (part du comité) 26 Assurances collectives (part du comité) 550 Salaire chef inspecteur.2,520 Régime Rentes du Québec (part du comité).318 Allocation automobile.5,700 Frais de vérification.6,975 Frais judiciaires.2,000 Gasoline., 2,325 Commission des Accidents du Travail 81 Total dépenses administration inspecteurs prévues.8 58,430 Comptes administration sécurité sociale: Salaires des préposés sécurité sociale S 1,710 Assurances collectives (purt du comité) 25 Régime Rentes du Québec (part du comité)._ 14 Commission des Accidents du Travail 4 Total dépenses administration sécurité sociulc prévues.8 1,753 Comptes dépenses membres du comité: Assemblées sous-comité dc finance.8 480 Assemblées spéciales.720 Assemblées sous-comité qualification de travail.480 Assemblées régulières jetons dc présences._.120 Assemblées régulières frais déplacements.600 Total dépenses membres du comité prévues.8 2,400 Comptes dépenses administration propriété: Éclairage.8 300 Chauffage.200 Entretien (matériel seulement).40 Réparation générale.150 Salaire du concierge.765 Taxes Municipales et scolaires.7,067 Total dépenses administration propriété prévues.8 8,522 Comptes dicers: Frais d'examens de qualifications du travail.8 6,850 Le sous-ministre, Robert Sauvé.Ministère du Travail ct de la Main-d'oeuvre, Québec, le 28 mars 1970.33856-0 Avis de prélèvement Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, l'honorable Jean Cournoyer, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q.1964, chapitre 143), que lc Comité paritaire de Auditor's fees.$ 400 Workmen's Compensation Commission 40 Estimated total, general administration expenses.8 29,344 Inspection administration expenses: Inspectors' salaries.$ 37,935 Unemployment Insurance (Committee's share).26 Group insurance (Committee's share) 550 Chief inspector's salary.2,520 Québec Pension Plan (Committee's share).318 Automobile allowance.5,700 Auditor's fees.6,975 Legal costs.2,(100 Gasoline.2,325 Workmen's Compensation Commission 81 Estimated total, inspection administration expenses.8 58,430 Social security administration expenses: Social security administration staff's salaries.8 1,710 Group insurance (Committee's share) 25 Quebec Pension Plan (Committee's share).14 Workmen's ComiKmsation Commission 4 Estimated total, sociul security administration expenses.S 1,753 Expenses, Committee members: Meetings, financial subcommittee.8 480 Special meetings.Meetings, competency examination subcommittee.480 Regular meetings, attendance fees.120 Regular meetings, travelling expenses 600 Estimated total, expenses, committee members.8 2,400 Expenses for administration of premises: Light.S 300 Heating.200 Maintenance (equipment only).40 General repairs.]50 Janitor's salary._ 765 Municipal and school taxes.7,067 Estimated total, expenses for administration of premises.8 8,522 Miscellaneous expenses: Competency examination expenses.S 6,850 Robert Sauvé, Deputy Minister.Department of Labour and Manpower, Québec, March 28,1970.338564 Notice of Levy Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.143), the Honourable Jean Cournoyer, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that the Parity Committee of the Glass Industry, Québec QUÉBEC OFFICIAI GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 2021 l'Industrie du Verre, district de Québec, établi en exécution du décret numéro 878 du 2 août 1930 et nmendements, a été autorisé par règlement npprouvé par l'arrêté en conseil numéro 1226 du 18 mars 1970, à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant les conditions ci-après décrites: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er avril 1970 au 31 décembre 1970; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 878 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 878 ct amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% du salaire établi dans le décret pour le salarié le moins rémunéré suivant le métier qu'ils exercent.c) Les salariés régis par ledit décret numéro S78 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à dc 1% dc leur rémunération.2.Mode de perception A chaque mois, l'employeur professionnel do't fournir au Comité paritaire, sur les formules fournies à cette fin par ledit comité, un rapport détaillé indiquant les heures de travail ct lc salaire gagné par chacun dc ses salariés régis par lc décret ct les sommes versées au Comité paritaire.Ce rapport dûment signé par l'employeur professionnel doit être accompagné des cotisations payables au Comité paritaire par l'employeur professionnel ct des salariés, toutes ces sommes doivent être payées en deniers ayant cours légal dans la province de Québec.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin dc chaque semaine, à même lc salaire gagné ou allocation duc à chacun dc ses salaries, les sommes qui reviennent au Comité paritaire à titre de prélèvement.Les cotisations doivent être payées mensuellement au Comité pnritaire entre le 1er et le 10 du mois suivant.Lc Comité paritaire a le droit et le pouvoir d'exiger l'asscrmcntation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi des décrets de convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au ministre du Travail ct dc la Main-d'oeuvre, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.Ci-anncxé, un état des revenus et des dépenses probables du Comité paritaire de l'Industrie du verre, district dc Québec, pour la période comprise entre le 1er avril ct le 31 décembre 1970.Comité paritaire de l'Industrie du verre, district de Québec Prévisions budgétaires pour la période du 1er avril 1970 au 31 décembre 1970.district (established in pursuance of Decree number 878 of August 2, 1950, as amended), has been authorized to levy dues on the professional employers, artisans and employees subject to the said decree, according to the conditions set forth below.A by-law approved by Order in Council number 1226, dated March 18, 1970, authorizes such levy.1.I)nés The contribution period extends from April 1, 1970, to December 31, 1970.The levy is carried out as follows: (a) Professional employers governed by said Decree number 878 and amendments must pay the Parity Committee on amount equivalent to Yi of 1% of their payroll for the employees subject to the said decree.(6) Artisans governed by said Decree number 878 and amendments must turn over to the Parity Committee an amount to Y of 1% of the salary which thc decree stipulates for thc lowest-paid employee in their trade.(c) Employees governed by said Decree number 878 and amendments must turn over to thc Parity Committee an amount equivalent to Yi of 1% of their wages.2.Collection of Dues Every month, the professional employer must submit a detailed report to the Parity Committee.This report should be made on forms supplies for this purpose by said Committee and should indicate thc hours worked, wages earned by each employee governed by the decree, together with thc sums forwarded to the Parity Committee.The dues, payable to thc Parity Committee by the professional employer and his employees, must accompany this rc|k>rt which has been duly signed by the professional employer.They shall be paid in currency considered as legal tender in Québec.At thc end of each week, thc amounts due thc Parity Committee shall be collected by the professional employer.Such amounts are deducted from thc salary or allowances earned by each employee.The contributions must be turned over to the Parity Committee between the 1st and 10th of the following month.The Parity Committee bus thc right and authority to exact a sworn attestation of the monthly reports whenever it deems it ndvisablc to do so.3.Financial report In compliance with thc provisions of the Collective Agreement Decrees Act, thc Parity Committee shall submit a quarterly financial report to thc Minister of Labour and Manpower on the following set dates: March 31st, June 30th, September 30th and December 31st of each year.An estimate of receipts nnd disbursements of the Parity Committee of thc Glass Industry, Québec district, for thc period extending from April 1, 1970, to December 31, 1970, is given below.Parity Committee of the Glass Industry, Québec district Estimate of revenue nnd expenditure for thc period extending from April 1.1970, to December 31, 1970. 2022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n\" 13 Sommaire: Comptes de dépenses administration générale.$2,147 Comptes de dépenses administration inspecteurs .900 Comptes dc dépenses membres du Co-mité.420 Comptes divers.120 Total des dépenses prévues.$3,587 Revenus: Cotisations patronales.$1,925 Cotisations ouvrières.1,925 Intérêts sur placements comptabilité générale.140 Total des revenus prévus.$3,990 Surplus prévu.8 403 Comptes dépenses administration générale: Salaire du Secrétaire Gérant.$1,800 Papeterie.45 Téléphone ct télégrammes.144 Frais postaux.25 Intérêts et frais de banque.5 Auditeur.128 Total dépenses administration générale prévues.$2,147 Comptes dépenses administration inspecteurs: Salaires des inspecteurs.$ 900 Total dépenses administration inspecteurs prévues.8 900 Comptes dépenses membres du comité: Assemblées régulières jetons dc présences $ 210 Assemblées régulières frais déplacements.210 Total dépenses membres du comité prévues.$ 420 Comptes divers: Frais d'examens de qualification du travail 8 120 Le sous-minislre, Robert Sauve.Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, Québec, le 28 mars 1970.33856-0 Summary: General administration expenses.82,147 Inspection administration expenses.900 Expenses \u2014 committee members.420 Miscellaneous expenses.120 Estimated total expenses.S3.58Ï Revenue: Employers' dues.$1,925 Employees' dues.1,925 Interest on investments - general accounting.140 Estimated total revenue.83,990 Estimated surplus.S 403 General administration expenses: Managing secretary's salary.SI ,800 Stationery.45 Telephone and telegrams.144 Postage.25 Banking, interest and costs.5 Auditor's fees.128 Estimated total, general administration expenses.82,147 Inspection administration expenses: Inspectors' salariés.8 900 Estimated total, inspection administration expenses.S 900 Expenses \u2014 committee members: Regular meetings, attendance fees.8 210 Regular meetings, travelling excuses- 210 Estimated total, expenses \u2014 Committee members.8 420 .1/ isccllaneous expenses: Competency examination expenses.S 120 Robert Sauvé, Deputy Minister.Department of Labour and Manpower, Québec, March 28,1970.338564 Liquidation \u2014 Avis de Winding up Notices La Cic de Téléphone de Disraeli Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires de « La Cie dc Téléphone de Disraeli », tenue à Sillery, le 10 novembre 1969, il a été résolu que les affaires de ladite compagnie soient liquidées, et que celle-ci soit dissoute, en vertu dc la Loi dc la liquidation des compagnies, et que M.Paul Morimanno a été nommé liquidateur.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.33853-0 1560-38 La Cic de Téléphone de Disraeli Notice is given that at a special general meeting of the shareholders of \"La Cie de Téléphone de Disraeli\", held at Sillcry, on November 10, 1909.it has been resolved that the affiairs of the said company be wound up and that it be dissolved, pursuant to the Winding-Up Act, and that Mr.Paul Morimanno has been appointed liquidator, Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.33853 1560-38 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 2023 Syndicat professionnel Association des chirurgiens dentistes du Québec Québec Dental Surgeons Association (Loi des syndicats professionnels) l,c ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives donne avis que le 6 mars 1970, il a autorisé le changement dc nom de |'t Association professionnelle des chirurgiens dentistes du Québec \u2014 The Professional Associa-lion «f Dental Surgeons of Québec », dont la constitution o été autorisée lc 6 juin 1966, et dont le siège social est situé à Montréal, en celui je « Association des chirurgiens dentistes du Québec \u2014 Québec Dental Surgeons Association », ct ce, en vertu dc la Loi des syndicats professionnels.Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Québec, le 17 mars 1970.U soiis-miiiislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PllILII'pk BoUCHARD.33837-u 82-66 Professional Syndicate Association des chirurgiens dentistes du Québec Québec Dental Surgeons Association (Professional Syndicales Acl) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, on March 6, 1970, he authorized thc change of name of \"Association professionnelle des chirurgiens dentistes du Québec \u2014 The Professional Association of Dental Surgeons of Québec\", the incorporation of which was authorized on June 6, 1966, and thc head office of which is situated in Montreal, to that of \"Association des chirurgiens dentistes du Québec \u2014 Québec Dental Surgeons Association\", and such, pursuant to the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, chapter 146.Québec, March 17, 1970.Ls-Piiilii'I'ic Bouchard, Depuly Minister of Financial Institulions, Companies and Cooperatives.33837 82-66 Société d'habitation du Québec Québec Housing Corporation Cité de Sherbrooke Adaption d'un programme de rénovation Conformément aux articles 33 et 34 de la Loi de lu Société d'Habitation du Québec (15-16 Elizabeth II, chapitre 55), avis public est, par les présentes donné que lc Conseil Municipal dc la cité de Sherbrooke a adopté, lors d'une assemblée spéciale tenue au lieu ordinaire îles séances du Conseil, lc 22 décembre 1969, lc règlement No 1953 décrétant un programme de rénovation pour partie de la zone St-François ct demandant à la Société d'Habitation du Québec et au lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver ledit programme.Lc territoire faisant l'objet de ce programme de rénovation est délimité par les rues Hébert, Kennedy.Conseil, Bowcn, Hubbard et la rivière St-François et les aires d'intervention comprennent les secteurs suivants: Secteur I.Délimité par la rue Bowcn, la rue Anutrong, la rivière St-François, la rue King est, la limite ouest du lot 438-1, les limites nord et est du lot 437, les limites est ct sud du lot 434, à l'est des limites ouest des lots 432 ct 433 et 431-1, partie de lu limite sud du lot 430 n.s.comprenant les lots 123, 424-1 à 424-12 inclusivement, 425-1 à 425-10 inclusivement, 420, 427, 428, 429 n.s.429-1, 430 n.s., 430-1, 431-2, 432-1.433-1, 434-1, 434 n.s.437 n.s.437-1 et 438-2.Secteur 2.Délimité par la rue Bowcn, les imites sud et ouest du lot 872, la limite nord du lot 873, la limite est des lots 888-A, 887 p., 886, 8S3.882, les limites nord et ouest du lot 887, la rue King est, la rivière St.François et la rue Bowcn, comprenant les lots 861, n.s., 861-1, 862, 863, 864, 865, 866, n.s., 866-1.867, 868.869, »'0.871, S72, 878.879, 881 à 887 inclusivement, »8 n.s.SS8-1, 888-2, 889, 890, 891-1, 892 n.s., §92-2, 893, 894, 895-1, 895-4-1, 895-5 n.s., 895-0-1.895-6.895-7, 895-8.City of Sherbrooke / m pleut at ion of a renewal program In conformity with article 33 and 34 of thc Québec Housing Corporation Act (15-16 Elizabeth II, Chapter 55) public notice is hereby given that the Council of the city of Sherbrooke at a special meeting held in the City Hall on December 22, 1969, adopted by-law No.1953 to implement a renewal program concerning the territory delimited by Hébert, Kennedy, Conseil, Bowen nnd Hubbard streets and by the St-Francis River, and thc nrcus of intervention includes the three following sectors: Sector 1.Bounded by Bowcn street, Armstrong street, the St-Francis River, the western limit of lot 438-1, thc northern nnd eastern limits of lot 437, the eastern and southern limits of lot 434, to thc cast of thc western limit of lots 432, 433 nnd 431-1, part of the southern limit of lot 431-1 and the western and southern limits of lot No.430 n.s.including thc following cadastral numbers: 423, 424-1 to 424-12 inclusively, 425-1 to 425-10 inclusively, 426, 427, 428, 429 n.s., 429-1, 430 n.s., 430-1, 431-2, 432-1, 433-1.434-1, 434 n.s., 437 n.s., 437-1 and 438-2.Sector 2.Bounded by Bowen Street, the south-earn and western limits of lot No.872, the north-earn limit of lot No.873, thc eastern limit of lots 888-A, 887 p., 886, 883, 882, thc northern ami western limits of lot 877, King street cast, the St-Francis River and Bowcn Street including the following cadastral numbers: 861 n.s., 861-1, 862, 863, 864, 865, 866 n.s., 866-1, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 878, 879, 881 to 887 inclusively, 888 n.s., 888-1, 888-2, 889, 890, 891-1, 892 n.s., 892-2, 893, 894, 895-1, 895-4-1, 895-5 n.s., 895-5-1, 895-6, 895-7, 895-8. 2024 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 18 Secteur 3.Délimité par la rue Kennedy sud, la limite sud d'une partie du lot 472, partie des lots 445, 446 et 447 ct la rue King est, comprenant les lots 475-1, 475-2, 475-3, 475-4, 475-5, 474, 473, partie 472 et partie des lots 445, 446 et 447.Les principaux travaux il exécuter sont l'achat et la démolition d'environ 113 bâtiments, la réfection des réseaux d'aqueduc, d'égouts, d'électricité, «le gaz ct de téléphone; la fermeture de la rue Windsor, la relocalisation du boulevard St-François nord ainsi que l'ouverture de deux rues entre la rue Bowen et lc boulevard St-François; ce programme comprend aussi la construction dc 425 logements et la rénovation dc 20 logements.Lea nouvelles réglementations et modifications aux règlements existants adoptées en vertu de ce programme et devant entrer en vigueur en vertu dc l'article 41 de la loi de la Société d'Habitation du Québec au moment ou lc territoire dans lequel elles doivent s'appliquer est décrété « zone dc rénovation », sont des amendements au règlement Xo 1071 de lotissement ct dc zonage.Les intéressés pourront consulter les documents constituant ce programme au bureau municipal des Services Techniques, au 1300 ouest rue Galt, aux heures normales d'ouverture des bureaux.Dc plus, les intéressés pourront se procurer au même endroit une ou des copies du programme de rénovât ion au prix unitaire dc $25.Enfin, les intéressés peuvent transmettre pur écrit leurs objections au programme à la Société d'Habitation du Québec, 1995 ouest, boulevard ('barest, Sainte-Foy, Québec 10 et ce, pas plus tard que le dix-huitième jour de mai 1970.Donné ù Sherbrooke, ce seizième jour de mars 1970.Le greffier, 38857-0 Henri-Paul Ëuond.Sector 3.Bounded by Kennedy Street, the southern limit of part of lot No.472, part of lots Nos.445, 446 and 447 and King Street east, including the following cadastral numbers: 475-1 475-2, 475-3, 475-4, 475-5, 474, 473, part of lots' 472,445, 446 and 447.The main works to be carried out are: buying and demolition of approximatly 113 houses, new networks of sewers, water, electricity, gas, telephone; closing of Windsor Street, relocation of St-Francis Boulevard North; the opening of two new streets between Bowen Street and St-Francis Boulevard.This program also includes thc construction of 425 dwellings and the renovation of 20 dwellings.The new by-laws and amendments to existing by-laws adopted by virtue of this program and coming into force as provided for by the article 41 of the Québec Housing Corporation Act at the time when thc territory in which to they are to apply is declared a \"renewal zone\" and amended by by-law No.1071, regarding zoning and land division.The documents forming this program may be consulted by all interested parties at the Municipal Technical Services, 1300, Gait West, during the normal business hours.Furthermore, interested persons may obtain at thc above address one or several copies of the renewal program for the price of 825 per copy.Finally, those interested may submit in writing to thc Québec Housing Corporation at 1995 Charest Boulevard West, Stc-Foy, Québec 10, P.Q., their objections to the renewal program, and this not later than thc eighteenth da v of May 1970.Given at Sherbrooke, this sixteenth day of March 1970.Hexhi-Paul Émonii, 33857-o .Town Clerk.Ministère des Affaires municipales Department of Municipal Affairs Ville de La Pocatière Avis est donné que, par l'arrêté en conseil No 1052 du 11 mars 1970 et conformément à l'article 43 de la Loi des cités et villes (S.R.Q.1964, chapitre 193), il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver le règlement No 5-69 du conseil municipal de la ville dc La Pocatière et de décréter que, à compter dc la date de la publication du présent avis, le territoire mentionné audit règlement et décrit ci-dessous est détaché dc la municipalité dc la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatièrc, comté de Kamou-raska, et annexé à la ville de La Pocatière.Ce territoire est le suivant: Description officielle des limites du territoire détaché de la municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et annexé à la ville de La Pocatière, dans le comté de Kamouraska.Un territoire faisant actuellement partie de la municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, comprenant en référence au cadastre officiai de ladite paroisse, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes ct futures ainsi que les chemins, rues, routes, cours d'eau ou parties c'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: Town of La Pocatière Notice is given that by Order in Council No.1052 of March 11, 1970 and in conformity with section 43 of the Cities and Towns Act (R.S.Q.1964, chapter 193), the Lieutenant-Governor m Council has been pleased to approve by-law No.5-69 of the municipal council of the town of La Pocatière and to decree that, from and after the date of the publication of the present notice the territory mentioned in the said by-law and described hereunder is detached from the municipality of the parish of Sainte-Anne-de-la-I'oca-tière, county of Kamouraska, and annexed to the town of La Pocatière.This territory is the following: Official description of the limits of the territory detached from the municipality of the parish of Sainte-Anne-de-la-Pocatière and annexed to the town of La Pocatière, in thc county of Kamouraska.A territory actually being part of the municipality of the parish of Sainte-Anne-dc-la-l'oca-tièrc, county of Kamouraska, including in reference to the official cadastre of the said parish, the lots or parts of lots and their subdivisions, present and future as well as the roads, streets, routes, water courses or parts of these, the whole enclosed within the limits hereafter described, to wit: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 2025 Parlant du milieu de l'embouchure de la rivière Saint-Jean sur la rive droite du fleuve Saint-Laurent; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: en suivant les limites actuelles de la ville de La Pocatière, la ligne médiane de la rivière Saint-Jean en remontant son cours jusqu'à sa première rencontre avec le prolongement de la ligne sud-ouest du lot 75; ledit prolongement ct ladite ligne sud-ouest du lot 75 ct ses prolongements à travers la rivière Saint-Jean; la ligne sud-ouest du lot 76, cette ligne traversant la route 2; la ligne sud-ouest du lot 75-A, cette ligne traversant la route 2A; la ligne sud-ouest du lot 74; puis laissant les limites actuelles de la ville dc La Pocatière, partie de la ligne separative des rangs I et II en allant vers le nord et le nord-est jusqu'à la ligne nord-est du lot 2; ladite ligne nord-est du lot 2 et son prolongement à travers la route 2; la ligne nord-est du lot 1 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du (iruml Ruisseau; la ligne médiane dudit ruisseau en descendant son cours jusqu'à la rive droite du fleuve Saint-Laurent, enfin, la rive droite du fleuve Saint-Laurent en allant vers le sud jusqu'au point de départ.Le sous-minislre des affaires municipales, 33746-0 Riciiakd Beaulieu.Ville dc Baie-Saint-Paul Comté de Chorlcvoix-Ouest Erratum Veuillez remplacer la description officielle parue dans lu Gazelle officielle du 10 juin 1961,volume 93, numéro 23, page 2665, par celle ci-dessous: Nouvelle description officielle des limites du territoire actuel de la ville de Baic-Saint-Pnid, comté de Charlevoix-Oucst.Le territoire uctuel de lu ville dc Baie-Saint-Paul, comté dc Charlevoix-Ouest, comprend en référence nu endastre officiel dc la paroisse dc llaic-Saint-Paul, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes ct futures, ainsi que les chemins, rues, routes, emprise de chemin de fer, rivières, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection dc la ligne separative des lots 632 et 633 avec la rive droite de la rivière du Gouffre; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: le prolongement dc la ligne separative des lots 632 ct 633 jusqu'à la ligne médiane de la rivière du Gouffre; ladite ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours ct la ligne médiane du chenal passant au nord-est dc l'île No 295 jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 368 et 369; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 346; ledit prolongement à travers les lots 36S, 367 et 366; ladite ligne nord-est du lot 346 et son prolongement jusqu'à la ligne ¦néiliane du ruisseau Rouge; la ligne médiane dudit ruisseau traversant les lots 311 et 308 ct jin chemin public jusqu'au côté sud dudit chemin ; es côtés sud ct sud-est de ce chemin jusqu'à la ligne nord-est du lot 305; les lignes nord-est ct sud-est dudit lot 305; partie dc la ligne nord-est et la ligne sud-est du lot 306; une ligne droite à travers le lot 303 ct un chemin public joignant I angle sud du lot 306 à l'angle est du lot 317; une Starting from thc middle of thc mouth of Saint-Jean River on the right shore of the St.Lawrence River; thence, successively, the following lines and demarcations: following the actual limits of the town of La Pocatière, the median line of Saint-Jean River flowing up its course to its first meeting with the prolongation of thc south-west line of lot 75; the said prolongation and the said south-west line of lot 75 and its prolongations across Saint-Jean River; thc southwest line of lot 76, this line crossing route 2; the south-west line of lot 75A, this line crossing route 2A; the south-west line of lot 74; then leaving the actual limits of the town of La Pocatière, part of the separative line of ranges I and II and going north and north-cast to the north-east line of lot 2; the said north-cast line of lot 2 and its prolongation across route 2; the north-east line of lot 1 and its prolongation to thc median line of ( irai id Ruisseau; the median line of the said stream flowing down its course to the right shore of the St.Lawrence River, finally, the right shore of the St.Lawrence River going south to the point of departure.Richard Beaulieu, 33746 Depuly M mister of Municipal Affairs.Town of Baie-St-Paul County of Charlcvoix-Wcst Erratum Kindly replace the official description published in the Official Gazelle of June 10, 1961, Volume 93, number 23, page 2665, by the following: New Official Description of the boundaries of the present territory of the town of Baie-Suint-Paul, county of Charlevoix-West.The present territory of the town of Baie-Saint-Paul, county of Charlevoix-West, comprises with reference to the official cadastre of the parish of Baic-Saint-Puul, the lots or parts of lots and their subdivisions present and future, as well as the roads, streets, routes, railroad rights of way, rivers, watercourses or parts thereof, the whole enclosed within the boundaries hereafter described, to wit: starting from the point of intersection of the division line of lots 632 and 633 from the right shore of du Gouffre River; thence, successively, the following lines nnd demarcations: the extension of the division line of lots 632 and 633 to thc median line of du Gouffre River; the said median line of the said river going downstream and the median line of the channel passing at the northeast of Island No.295 as far as the extension of the division line of lots 368 and 369; the said extension and the said lot division line as far as the extension of the northeast line of lot 346; the said extension through lots 368, 367 and 366; the said northeast line of lot 346 and its extension to the median line of Ruisseau Rouge; the median line of the said stream crossing lots 311 and 308 a public road as far as the south side of the said road; the south nnd southeost sides of this road as far as the northeast line of lot 305; the northeast and southeast lines of said lot 305; part of the northeast line and the southeast line of lot 306; a straight line crossing lot 303 and a public road joining the south angle of lot 306 with the cast angle of lot 317; a straight line crossing du 202G GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 88 mars 1970, 108' année, n° 13 ligne droite à travers la rivière du Gouffre jusqu'au point d'intersection de la rive droite de ladite rivière avec lc prolongement dc la ligne sud-ouest du lot 317; la rive droite de la susdite rivière en descendant son cours jusqu'au point où clic se confond avec la rive du fleuve Saint ¦ Laurcnt; la rive dudit fleuve jusqu'au prolongement dc la ligne sud-ouest du lot 983; ledit prolongement à travers les lots 1177, 1175, 1173, 1171, 1169, 1167, 1165, 1163, 1161, 1159, 1157, 1155.1153, 1151, 1149.1147, 1144, 1140, 1134, 1131, 1117, 1116, la rivière du Moulin, les lots 931 et 956 ct ladite ligne sud-ouest du lot 9S3; une ligne droite traversant les lots 810, 811, 813.729, 724 et partie du lot 723 jusqu'au coin sud-ouest du lot 778; la ligne sépurant le lot 778 des lots 723, 719, 718 et 716; partie dc la ligne séparutive des lots originaires 698 et 716 jusqu'au prolongement duns ledit lot 698 dc la ligne nord-ouest dc l'ancienne propriété de Charles Trembluy aujourd'hui appartenant ù ltcrchmans Bcllcy; ledit prolongement et la ligne nord-ouest de ladite propriété jusqu'au côté sud-ouest de la rue Sain l -Jeun-Baptiste; une ligne droite traversant celte rue et le lot 673 jusqu'au coin nord dudit lot; une ligne séparant le lot 675 «les lots 685 et 679 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du ruisseau à Renaud; In ligne médiane dudit ruisseau en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 649; ledit prolongement et Indite ligne nord-ouest dudit lot 649, enfin les lignes ouest et nord du lot 633 jusqu'au point dc dépurt; lesquelles limites définissent le territoire actuel dc In ville dc Bnie-Stiinl-Paul, dans lc comté dc Churlevoix-Ouest.Gouffre River to the point of intersection of the right shore of thc said river with the extension of the southwest line of lot 317; thc right shore of the aforesaid river going downstream to t|lc point where it meets the Saint Lawrence River hank; the hank of the said river to the extension of the southwest line of lot 983; the suid extension crossing lots 1177, 1175, 1173, 1171, 11439, 1167 1165, 1163,4161, 1159, 1157.1155, 1153, Hal' 1149, 1147, 1144, 1140, 1134, 1131, 1117.Uio] du Moulin River, lots 931 and 956 and the said southwest line of lot 983; a straight line crossing lots 810, 811, 813, 729, 724 nnd part of lot 723 to the southwest corner of lot 778; thc line separating lot 778 from lots 723, 719, 718 and 716; part of the division line of original lots 698 and 716 to the extension into the said lot 698 of thc north-west line of thc former property of Charles Tremblay now belonging to licrclunan- Belley; the said extension and the northwest line of the said property to thc southwest side of Saint-Jean-Baptiste Street; u straight line crossing (his street and lot 673 to the north corner of the said lot; a line separating lot 675 from lots 6S5 and 679 and its extension to the médian line of Ruisseau à Renaud; thc median line of llie said stream going upstream to thc extension of the northwest line of lot 649; the said extension and thc said northwest line of the said lot 649.finally the west and north lines of lot 633 to the starling point; the said boundaries describe thc present territory of the town of Baic-Saint-Paul, in the county of Charlevoix-West.Ministère des Terres et Forêts, Service de l'Arpentage et de la Géodésie, QuélK-c, lc 27 février 1970.Préparé par l'arpenleur-gêomctrc, Gerard Tànguay.Copie conforme.Approuvé par le directeur du service, 33746-0 Maurice Di'vai.Department of Lands and Forests, Land-surveying and Geodesy Branch.Québec.February 27, 1970.Prepared by Land-surveyor, Gerard Tangûay.True copy Approved by Branch Director.33746 Maurice Duval.Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Quebec.[L.S.) ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada ct de ses autres royaumes ct territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut.Lettres patentes ATTENDU que chacun des conseils municipaux dc la cité de Grand'Mère, comté de Champlain, ct dc la paroisse de Sainte-Flore, comté de Saint-Maurice, a adopté, à la majorité absolue dc ses membres, un règlement autorisant ln présentation d'une requête conjointe nu lieutenant-gouverneur en conseil lc priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant ces municipalités ct créant une nouvelle municipalité sous l'autorité de la Loi dc la fusion volontaire des municipalités; Attendu que les publications requises par l'article 6 de la loi précitée ont été faites; Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Crac* of God, of the United Kingdom, Canada and her other Realms and Territories.(Juccn, Head of thc Commonwealth.Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern.Greeting.Letters patent Whereas each of the municipal Councils of the City of Grand'Mère, county of Champlain, and of the parish of Saint-Flore, county of Saint-Maurice, adopted, by absolute majority of its members, a by-law authorizing thc presentation of a joint petition to the Lieutenant-Governor in Council, asking him to grant letters patent amalgamating thc said municipalities, and creating a new municipality under the Voluntary Amalgamation of Municipalities Act; Whereas thc publication required by section 6 of thc aforementioned act have been man*! QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 2027 ATTENDU qu'un exemplaire dc la requête conjointe, en date du 9 octobre 1969, a été transmis au ministre des affaires municipales ct it la Commission municipale de Québec; Attendu qu'aucune demande d'enquête n'a été fuite à la Commission municipale dc Québec et que cette dernière n'a pas tenu d'audition publique; Attendu qu'il y a lieu de donner suite à la requête conjointe.A ces causes du consentement et dc l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant lc numéro 444, en date du 4 février 1970, Nous avons décrété ct ordonné ct, par les présentes, décrétons ct ordonnons que des lettres patentes soient octroyées, fusionnant la cité de Grand-Mère, comté de Champlain et la paroisse de Sainte-Flore, comté de Saint-Maurice, et créant une nouvelle municipalité dc ville, sous le nom de « Ville de Grand-Mère », aux conditions mentionnées dans la requête conjointe.Ces conditions sont les suivantes: 1.Lc nom de la nouvelle municipalité est < Ville de Grand'Mère » ; 2.Lc_ territoire de la nouvelle municipalité est celui qu'a décrit officiellement le ministère des terres et forêts, le 7 janvier 1970; cette description apparaît dans l'annexe «A» du décret ri-dessus mentionné; 3.bu nouvelle municipalité est régie pnr lu Loi des cités ct villes; -I.Les dispositions législutives spéciales suivantes (pli s'appliquaient, avant la fusion: a) Quant à la cité de Grand'Mère Les articles 38, 39, 53 ct 55 du chapitre 54 des lois de 1910.Les articles 2, 7, 8, 11 ct 12 du chapitre 67 des lois de 1912, session 2.Les articles 3 et 5 du chapitre 113 des lois dc 1931-1932.L'article 1 du chapitre 97 des lois dc 1934.Les articles 3 ct 6 du chapitre 75 des lois dc 1952-1953.L'article 2 du chapitre 87 des lois de 1955-1956.//) Quant à la paroisse dc Sainte-Flore Le chapitre 152 des lois de 1957-1958.s'appliquent ù la nouvelle ville; 5.Jusqu'à la première élection générale, le conseil provisoire sera composé de dix (10) membres, soient le moire actuel de la cité de Grand'Mère qui deviendra lc maire de la nouvelle ville et de neuf (9) conseillers dont les six (6) conseillers actuellement en fonction dans la cité de Grand'Mère et trois (3) conseillers choisis par le conseil dc la paroisse dc Sainte-Flore parmi les membres dc ce conseil ct qui seront choisis lors d'une séance tenue ù cette fin à compter du 17 novembre 1969.Le conseil provisoire remplit nu moyen d'une résolution toute ou toutes vacances survenant S ces trois charges a va ni In première élection générale en choisissnnt les titulaires parmi les personnes éligiblcs dc l'ancienne municipalité de la paroisse dc Sainte-Flore l force in the municipality of the City of Grand-Mère forms thc valuation roll of thc new city.(/) The sections of the by-laws of the parish of Sainte-Florc concerning compensation for water, and those respecting thc levying of taxes for QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 2029 dangcs, les taxes locatives et les taxes commerciales ne seront en vigueur que jusqu'à l'adoption du premier budget de la nouvelle ville: .i ce moment, la nouvelle ville réglementera les taxes concernant les item ci-haut mentionnés, à être exigées sur tout le territoire de la nouvelle ville: 13.Les règlements actuels de chaque municipalité demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, amendés ou abrogés par le nouveau conseil; 14.La Cour municipale actuelle dc la cité de Grand'Mère aura juridiction sur tout le territoire de la nouvelle ville; 15.Les fonctionnaires actuels de la cité dc Grand'Mère deviennent les fonctionnaires de la nouvelle ville; 16.Lc fonds industriel dc la cité dc Grand'Mère ct celui dc la paroisse dc Sainte-Flore formeront le fonds industriel de la nouvelle ville et tel fonds pourra être utilisé dans tout le territoire de la nouvelle ville; 17.L'année financière de la nouvelle ville commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre dc chaque année.Ex foi dk quoi, Nous uvons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur iccllcs apposer le grand sceau dc Notre province dc Québec; Têuoin: Notre très fidèle ct bien-aimé l'honora-ble Hugues Lapointe, cp., ch., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce quatrième jour de février en l'année mil neuf cent soixante-dix de l'ère chrétienne et de Notre Règne la dix-huitième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Lucien Darveau.Avis de l'octroi des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi dc la fusion volontaire des municipalités.Le sous-minislre des affaires municipales, 33746-0 Richard Beaulieu.refuse removal, rental and commercial taxes, shall remain in force only until adoption of the new city's first budget; at such time, thc new city shall regulate thc taxes concerning thc above-mentioned items, to be exacted from thc entire territory of the new city; 13.The present by-laws of each municipality shall be in force until they have been modified, amended or repealed by the new Council; 14.The present Municipal Court of thc City of Grand'Mère shall have jurisdiction in the entire territory of thc new city; 15.Thc present functionaries of thc City of Grand'Mère shall become the functionaries of the new city; 16.The industrial fund of the City of Grand'Mère and that of thc parish of Sainte-Flore shall form thc industrial fund of the new city, and such fund may be used in the entire territory of thc new city; 17.The fiscal year of the new city shall begin on January 1st and end on December 31st of each year.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and thc Great Seal of Our Province of Québec to l)c hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved, thc Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Building, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this fourth day of February, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy, and in thc eighteenth year of Our Reign.By command, Lucien Darveau, Assistant Deputy Attorney General.Notice of the granting of thc above letters patent is given pursuant to the provisions of section 13 of thc Voluntary Amalgamation of Municipalities Act.Richard Beaulieu, 33746 Depuly Minister of Municipal Affairs.Proclamations Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.|L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grace de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada ct dc ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui les présentes verront ou qu'icclles pourront concerner, Salut.Proclamation ¦ Attendu que c'est Notre désir et Notre bon plaisir dc rencontrer aussitôt que possible le peu-pic de lu province dc Québec et d'obtenir son avis exprimé en parlement; A ces causes, sur l'avis du Conseil exécutif de la province de Québec, Nous convoquons par les présentes une nouvelle législature de la pro- Proclamations Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas We arc desirous and bave decided to meet as soon as possible thc People of thc Province of Québec and to have their advice, expressed in Parliament; Therefore, by and with the advice of the Executive Council of the Province of Québec, We do hereby convene a new Legislature of the 2030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n\" 13 vince pour le vingtième jour de moi prochain et mandons et ordonnons à ses membres dc s'assembler à cette date au palais législatif, en la ville dc Québec.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer lc grand sceau ec; témoin : Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province dc Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce onzième jour de mars en l'année mil neuf cent soixante-dix de l'ère chrétienne et dc Notre Règne la dix-neuvième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.33824-0 Lucien Darveau.Soumissions Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of thc United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas, pursuant to section 69 of chapter 20 of the Revised Statutes of Québec, 1964, the Lieutenant-Governor may, at any time, by proclamation, direct an extraordinary term of the Court of Queen's Bench (Crown side) to l>c held in and for any district as a criminal court; Whereas it is deemed expedient to direct such an extraordinary term in the district of Three Rivers.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 1080 dated March 11, 1970, We have decreed and ordered, and hereby decree and order than an extraordinary term of the Court of Queen's Bench (Crown side) sitting as a criminal court, in the district of Three Rivers, l>c held as from May 4, 1970, opening date of said term.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern arc hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, Wc have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved thc Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Quéliec.Given at Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this eleventh day of March in the year of Our Ix>rd one thousand nine hundred and seventy nnd in thc nineteenth year of Our Reign.By command, Lucien Darveau, 33824 Assistant Deputy Attorney General.Tenders Ville de Mistassini Town of Mistassini Comté de Roberval County of Roberval Avis public est par les présentes donné que des Public notice is hcrebyTgiven that sealed soumissions cachetées ct endossées « Soumissions tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be pour obligations » seront reçues par le'soussigné received by the undersigned Germain Lavoie, 2034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' aimée, n\" 13 Germain Lavoic, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, 173, boulevard Saint-Michel, case postale 219, Mistassini, comté de Roberval, P.Q., jusqu'à 7 heures 30 du soir, mardi, le 14 avril 1970, pour l'achat dc $75,000 d'obligations dc la ville dc Mistassini, comté île Robcrval, datées du 1er mai 1970 ct remboursables par séries du 1er mai 1971 au 1er mai 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8¥>%, ni supérieur à 914%, payable semi-annuellcmcnt les 1er mai et 1er novembre dc chaque année1.Lc taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans le présent avis.Règlement no: 64 \u2014 $75,000 \u2014 renouvellement d'emprunt.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1970.Tableau d'amortissement \u2014 $75,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 1971 .82,000 1er mai 1972 .2,000 1er mai 1973 .2,500 1er mai 1974 .2,500 1er mai 1975 .2,500 1er mai 1976 .2,500 1er mai 1977 .3,000 1er mai 1978 .3,000 1er mai 1979.3,500 1er mai 1980.3,500 1er mai 1981.3,500 1er mai 1982 .4,000 1er mai 1983.4,000 1er mai 1984.4,500 1er mai 1985.4,500 1er mai 1986 .5,000 1er mai 1987.5,000 1er mai 1988 .5,500 1er mai 1989.6,000 1er mai 1990.6,000 Secretary-Treasurer, Town Hall, 173 Saint-Michel Boulevard, Post Office Box 219, Mistassini, County of Robcrval, P.Q., until 7:30 o'clock, p.m., on Tuesday, April 14, 1970, for the purchase of an issue of 875,000 of bonds for the Town of Mistassini, County of Roberval, dated May 1, 1970 and redeemable serially from May 1, 1971 to May 1, 1990 inclusively, with interest at a rate not less than 8^%, nor more than 9Yi%, payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rale of interest may be thc same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on thc tabic of redemption in this notice.By-law No.64 \u2014 S75.000 \u2014 renewal of n loan.For adjudication only, interest shall be calculated as from May 1, 1970.Table of redemption \u2014 $75,000 \u2014 20 yeah Year Capital May 1,1971.82,0011 May 1, 1972 .2.001) May 1,1973 .2,500 May 1,1974 .2,500 May 1, 1975 .2,500 May 1,1976 .2,500 May 1,1977.3,000 May 1, 1978.3,000 May 1, 1979 .3,500 May 1,1980.3,500 May 1, 1981.3,500 May 1, 1982 .4,00(1 May 1,1983.4.00(1 May 1, 1984.4,500 May 1,1985.4,50(1 May 1,1986 .5.0011 May 1,1987 .5,0011 May 1, 1988 .5.50(1 May 1,1989 .6.000 May 1, 1990 .6.000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie ct l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec lc solde à courte échéance 5 ans pour une partie ct l'autre partie à terme fixe 20 ans.6° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie ct l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans lc cas des paragraphes 4°, 5° ct 6°, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $6,000, et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans lc présent nvis, ct en commençant par les dernières années d'échéances.Également les obligations émises à courte échéunec 5 ans ou 10 uns, ne devront comporter que des amortissements annuels entiers, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant In partie qui sera à terme fixe 20 ans.Moreover, the following terms and conditions only shall l>c considered.(1) Five-year, 10-year or 15-year short-term serial bonds.(2) Ten-year serial bonds with thc balance as 20-year fixed-term bonds; (3) Ten-year serial bonds with the balance as 5-ycnr short-term bonds; 4.Ten-year serial bonds with the balance as 10-year short-term bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part; (5) Ten-year serial bonds with the balance as 5-ycnr short-term bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part; (6) Five-year short-term serial bonds for one part and 20-year fixed-term lwnds for the other part.However, as far as paragraphs 4, 5 ami (i are concerned, thc 20-year fixed-term bonds should be for nn nmount of not less tlinn $6,000 and if greater than the latter amount, the snid part should include one only or several complete annual amortizations, bearing in mind the table of maturities appearing in this notice and starting by the last years of maturities.Also, the 5-year or 10-ycar short-term bonds shall include complete annual nmortizntions only, nnd starling with the last years of maturities, excluding the 20-year fixed-term part. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 2035 Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage A payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y u lieu, par chèque visé, payable au pair à Mistassini.Le capital ct les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec dc la banque dont lc nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lcsdites obligations ne seront pas rachctablcs par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries ct terme fixe 20 ans, pour un montant égal à $0,000.Toutefois si elles sont émises en partie A terme fixe 20 uns pour un montant supérieur à $6,000, les obligations uinsi émises seront rachctablcs par anticipation, au pair, lc 1er mai dc chaque année pour lc montant annuel requis pmu- les 6ns de l'amortissement dc l'émission, conformément au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égul à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séiincc du conseil, qui sera tenue, mardi, le 14 avril 1970, à 7 heures 30 du soir, Hôtel dc ville, 173, boulevard Saint-Michel, case postule 21!), Mistassini, comté dc Roberval, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucuno «les soumissions.Mistassini (Comté «lc Roberval), ce 19 murs 1970.Le secrétaire-trésorier, Germain Lavoie.Hotel de ville, 173, boul.St-Michcl, C.P.219, Mistassini (Robcrval), P.Q.Téléphone: 276-3685.code 418.33876-n However, lenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terras, save in the cases of the exceptions stipulated above.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Mistassini.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they arc issued serially or serially and us 20-ycur fixed-term bonds for an amount equal to $6,000.However, should they be issued partly as 20-ycur fixed-term bonds for an amount greater than $6,000, the bonds so issued shall be redeemable, by anticipation, at par, on May 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the table of maturities of the issue appcuring in this notice.Each tender must be accompanied by u ccrtifie«l cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their «lelivery is included or not in the price of the tender.The lenders will be opened and considered ut u meeting of the council to be held on Tuesday, April l4, 1970, ut 7:30 o'clock, p.m., at the Town Hall, 173 Saint-Michel Boulevard, Post Office Box 219, Mistassini, County of Roberval, P.Q.Thc council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Mistassini (County of Robcrval), March 19, 1970.Germain Lavoie, Secretary-Treasurer.Town Hall, 173 St-Michel Boul.P.O.Box 219, Mistassini (Roberval), P.Q.Telephone : 276-3685, c«xlc 418.33876 Ville de Mont St-llilaire Comté dc Rouville Avis public est par les présentes donné «pic îles soumissions cachetées et endossées « Soumissions |)our obligations » seront reçues par le soussigné Yves ljicroix.Hôtel de Ville, 100, boulevard du Centre Civique, Mont St-Hiluirc.comté de Rouville, P.Q.jusqu'à 8.30 heures du soir, lundi, le 13 avril 1970, pour rachat de $631,500 d'obligations de lu ville de Mont-St-Hiluire.comté dc Rouville, datées «lu 1er mai 1070 et remboursables par séries du 1er mai 1971 au 1er mai 1990 inclusivement, avec intérêt A un taux non inférieur A 8J-j%, ni supérieur A 9/2%.payable semi-nnnucllenient les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à ¦ 11.i¦ 111¦ ¦ taux différent doit couvrir un ou îles amortissements annuels entiers, tel «nie montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1970.Tableau d'amortissement \u2014 $831,500 \u2014 20 ans Annie Capital 1er mai 1971.$24,500 1er mai 1972 .26,000 1er mai 1973 .27,000 Urinai 1974 .28,000 1er mai 1975 .28,000 Town of Mont St-lliluire County of Rouville Public notice is hereby given that scuied tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Yves Lacroix, Town Hall, 100 Civic Centre Boulevard, Mont-St-Hiluire, county of Rouville, P.Q., until 8:30 o'clock p.m., Monday, April 13, 1970, for the purchase of an issue of 8631,500 of bonds of the town of Mont-St-Hiluire, county of Rouville, dated May 1, 1970 and redeemable serially from May 1, 1971 to May 1, 1990 inclusively, with interest at a rate of not less than 8J^%, nor more than 9}\u2022>%, puyuble semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rote be used, the amount issued at euch different rutc must cover one or several complete annual amortizations, as shown on thc table of redemption of this notice.For adjudication only, interest will be calculated as from May 1, 1970.Tabic of redemption \u2014 $631,600 \u2014 20 years Year Capital May 1, 1971.$24,500 May 1, 1972 .26,000 May 1, 1973 .27.000 Mav 1,1974 .28,000 May 1,1976 .28,000 2036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 18 1er mai 1976.$25,000 1er mai 1977 .26,000 1er mai 1978 .27,000 1er mai 1979 .28,000 1er mai 1980 .29,000 1er mai 1981.32,000 1er mai 1982.33,000 1er mai 1983 .35,000 1er mai 1984.36,000 1er mai 1985 .37,000 1er mai 1986.39,000 1er mai 1987 .41,000 1er mai 1988 .42,000 1er mai 1989 .44,000 1er mai 1990 .24,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde ù terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde il courte échéance 10 ans jiour une partie ct l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie ct l'autre partie à terme fixe 20 ans.6° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie ct l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5° et 6°, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 87,000 et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, ct en commençant par les dernières nnnées d'échéances de la partie renouvelable ci-après mentionnée.Également, les obligations émises à courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements unnuels entiers, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant la partie qui sera à terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément ù la loi.L'échéance du 1er mai 1990 au montant dc 824,000 comprend un solde dc $7,000 renouvelable pour une période additionnelle dc 10 ans, et échéant comme suit: Année Capital 1er mai 1991.$ 500 1er mai 1992 .500 1er mai 1993 .500 1er mai 1994 .500 1er mai 1995 .500 1er mai 1996 .500 1er mai 1997.1,000 1er mai 1998.1,000 1er mai 1999.1,000 1er mai 2000.1,000 L'adjudicataire s'engage il payer les obligations, capital ct intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair il Mont-Saint-Hilaire.Lc capital ct les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.May 1, 1976.$25,000 May 1, 1977.26,000 May 1, 1978 .27,000 May 1, 1979.28,000 May 1, 1980.29,000 May 1, 1981.32,000 May 1, 1982 .33,000 May 1, 1983.35,000 May 1, 1984 .36,000 May 1, 1985 .37,000 May 1, 1986.39,000 May 1, 1987 .41,000 May 1, 1988 .42,000 May 1, 1989.44,000 May 1, 1990 .24.5(H) Moreover, the following terms and conditions only shall be considered: (1) Five-year, or 10-year or 15-year short-term serial bonds.(2) Ten-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.(3) Ten-year serial bonds with thc hnluncc as 5-ycar short-term bonds.j (4) Ten-year serial bonds with the bulancc as 10-ycar short-term bonds for one part und 20-year fixed-term bonds for the other part.(5) Ten-year serial bonds with thc balance as 5-year short-term bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for thc other part.(6) Five-year short-term serial bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.However, in thc case of paragraphs (4), (5) and (6), the 20-year fixed-term bonds shall lie for an amount of not less than $7,000, and if greater than the latter amount, said part must comprise only one or more complete iinnual amortizations, taking into account the table of maturities appearing in this notice und starting with the last years of maturities in the renewable part hereinafter mentioned.Also, 5-yeur or 10-year short-term bonds shall comprise only entire annual amortizations, and starting with the kst years of maturities, excluding thc 20-ycur fixed-term part.However, tenders shall l>c sent for one of the above methods of issue only, and they shall comprise one only of the terms, save in thc case of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The May 1, 1990 maturity in the amount of $24,000 comprises a balance of $7,000 renewable for an additional 10-year period, and maturing as follows: Year Capital May 1, 1991.$ 500 May 1, 1992.5(h) May 1, 1993.500 May 1, 1994 .500 Mav 1, 1995.500 May 1, 1996.50(1 May 1, 1997.1,000 May 1, 1998.1.000 May 1, 1999.1,000 May 1, 2000.1.000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any.by certified cheque payable at par at Mont-Saint-Hilaire.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 2037 Lcsditcs obligations ne seront pas rachctablcs pur anticipation si elles sont émises par séries ou en séries ct terme fixe 20 ans, pour un montant égul ou moindre de $24,000.Toutefois, si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un\" montant supérieur à $24,000, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er mai dc chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément aux tableaux d'échéances dc l'émission apparaissant duns le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si lc prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment tic leur livraison.Lcsditcs obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 154 \u2014 $256,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 156 (157) \u2014 $81,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 260 \u2014 $215,000 \u2014 consolidation dc dettes; 263 \u2014 $29,000 \u2014 confection du rôle d'évaluation; 271 \u2014 $20,000 \u2014 aqueduc; 285 \u2014 $23,000 \u2014 refinancement du règlement f 154; 286 \u2014 $7,000 \u2014 refinancement des règlements § 156 et 157.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 13 avril 1970, a 8.30 heures du soir, Hôtel dc Ville, 100, boulevard du Centre Civique, Mont-St-Hilaire, comté de Rouville, P.Q.Le conseil se réserve lc droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Mont-St-Ililairc (Comté de Rouville), ce 16 murs 1970.Le secrétaire-trésorier, Yves Lacroix.Hôtel de Ville, 100, boul.du Centre Civique, Mont-St-Hilairc (Comté de Rouville), P.Q.Téléphone : 467-2854.code 514.33«77-o The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and for 20-yenr fixed-term bonds for an amount equal to or less than $24,000.However, should they be issued partly for 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $24,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on May 1st of each year for thc annual amount required to amortize the issue, pursuant to thc tables of redemption of the issue appearing in this notice.Each tender must l>e accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of thc issue, and must specify whether interest accrued on thc bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tenders.The said bonds will be issued under the following by-laws: 154\u2014 $256,500 \u2014 loan renewal; 156 (157) \u2014 $81,000 \u2014 loan renewal; 260 \u2014 $215,000 \u2014 debt consolidation; 263 \u2014 $29,000 \u2014 making of a valuation role; 271 \u2014 $20,000 \u2014 aqueduct; 285 \u2014 $23,000 \u2014 by-law f 154 refinancing; 286 \u2014 87,000 \u2014 by-laws f 156 and 157 refinancing.Tenders be opened and considered at a meeting of thc council to be held Monday, April 13, 1970, at 8:30 o'clock p.m., at the Town Hall, 100 Civic Centre Boulevard, Mont-St-Hilaire, county of Rouville, P.Q.The council does not bind itself to accept thc highest or any of the tenders.Mont-St-Hilnirc (County of Rouville), March 16, 1970.Yves La choix, Secretary-Treasurer.Town Hall, 100 Civic Centre Boulevard, Mont-St-Hilaire (County of Rouville), P.Q.Telephone: 467-2854, code 514.33877 Ville de Roscmère Comté dc Terrebonne Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées * Soumissions pour obligations » seront reçues pur le soussigné Mme Pli.Gardiner, grellicr, jusqu'à 5 heures de l'après-midi, Hôtel dc ville, 186, rue Philippe, Roscmère, comté de Terrebonne, P.Q., ct par après jusqu'à 8 heures du soir, Salle du Poste de Police et Feu, 428, Grande-Côte, Roscmère, comté de Terrebonne, P.Q., lundi, le 13 avril 1970.pour l'achat de $424,000 d'obligations dc la ville de Roscmère, comté de Terrebonne, datées du 1er mai 1970 ct remboursables pur séries du 1er mai 1971 au 1er mai 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur n 8)4%.supérieur à 914%, payable semi-annuel-lcment les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Lc taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un tuux est utilisé, lc montant émis ù chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé ù compter du 1er mai 1970.Tableau d'amortissement \u2014 S424.OO0 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 1971.$ 9,000 1er mai 1972 .9,000 1er mai 1973.10,000 1er mai 1974.11,000 1er mai 1975.12,000 Town of Hose mere County of Terrebonne Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Mrs.Ph.Gardiner, city clerk, until 5:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 186 Philippe Street, Roscmère, county of Terrebonne, P.Q., anil thereafter until 8:00 o'clock in the evening, at the Police and Fire Station Hall, 428 Grande-Côte, Roscmère, county of Terrebonne, P.Q., Monday, April 13, 1970 for the purchase of $424,000 of bonds of the town of Roscmère, county of Terrebonne, dated May 1, 1970 and redeemable serially from May 1, 1971 to May 1, 1990 inclusively, with interest at a rate of not less than 8H%, nor more than 9Vi%, payable semi-annually on May 1st and November 1st each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more thun one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual amortizations, as shown on the table of redemption of this notice.For adjudication only, interest will be calculated as from May 1, 1970.Table of redemption \u2014 S/,24,000 \u2014 20 years Year Capital May 1, 1971.8 9,000 May 1,1972 .9,000 May 1, 1973.10,000 May 1,1974.11,000 Mav 1,1975.12,000 2038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n\" 18 1er mai 1976.$ 13,000 1er mai 1977.14,000 1er mai 1978.15,000 1er mai 1979.16,000 1er mai 1980.18,000 1er mai 1981.6,000 1er mai 1982.7,000 1er mai 1983.8,000 1er mai 1984.8,000 1er mai 1985.9,000 1er mai 1986.10,000 1er mai 1987.10,000 1er mai 1988.11,000 1er mai 1989.12,000 1er mai 1990.216,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 uns ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde ù terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 uns avec le solde à courte échéance 5 uns.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde ù courte échéance 10 nus pour une partie ct l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans uvec le solde ù courte échéance 5 uns pour une partie et l'autre partie ù terme fixe 20 uns.6° Obligations échéant en séries uvec courte échéance 5 ans pour une partie ct l'autre partie ii terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le eus des purugraphes 4°, 5° ct 6°, les obligations échéant ù terme fixe 20 uns ne devront pas être pour un montant inférieur ù 828,000 et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant pur les dernières années d'échéances de la purtic rcnouvcluble ei-après mentionnée.Egalement, les obligations émises ù courte échéance 5 nns ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements annuels entiers, ct en commençant par les dernières années d'échéances excluant ln partie qui sera ù terme fixe 20 nns.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-hnut ct ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera fuite conformément ù la loi.L'échéance du 1er mai 1990 au montant de 8216,000 comprend un solde de $203,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 nns, et échéant comme suit: Année Capital 1er mai 1991.$14,000 1er mai 1992.15,000 1er mai 1993.16,000 1er mai 1994.18,000 1er mai 1995.19,000 1er moi 1996 .21,000 1er mai 1997 .22,000 1er mai 1998.24,000 1er mai 1999 .26,000 1er mai 2000 .28,000 L'adjudicataire s'engage ù payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Roscmère.Lc capital ct les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Quél>ec de la May 1, 1976.$ 13,000 May 1,1977.14,0110 May 1, 1978.15,000 May 1, 1979.16,000 May 1, 1980.18,000 May 1, 1981.6,000 May 1, 1982.7,000 May 1, 1983.8.000 May 1, 1984 .8,000 May 1, 1985 .9.000 May 1,1986.10,000 May 1, 1987.10,000 May 1, 1988.11,000 May 1, 1989.12,000 May 1, 1990 .216.000 Moreover, the following terms and conditions only shall be considered: (1) Five-year, or 10-year or 15-year short-term serial bonds.(2) Ten-year serial bonds with the balance as 20-ycur fixed-term bonds.(3) Ten-year scriul bonds with the balance as 5-ycnr short-term bonds.(4) Ten-year serial Iwnds with thc balance as 10-year short-term for one |>urt and 20-yosr fixed-term bonds for the other part.(5) Ten-year serial bonds with the balance as 5-ycnr short-term bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.(6) Five-year short-term serial bonds tor one part and 20-yenr fixed-term l>oncriod, anil maturing us follows: Year < 'apilal May 1, 1991.814.000 May 1,1992.15,0(10 May 1,1993.16.000 May 1, 1994.18,000 May 1,1995.19.000 May 1,1996 .21.000 May 1,1997 .22.000 May 1,1998 .24.000 May 1,1999 .20,000 May 1,2000 .28.00(1 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any.by certified cheque payable at pur at Rosemèrc, Capital and interest are payable at all branche» in the Province of Québec of thc bank mentioned QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, Mardi 28, 1970, Vol.102, No.13 2039 banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lcsditcs obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries ct terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre de $216,000.Toutefois, si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $216,000 les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er mai de chaque année pour le niontant annuel requis pour les fins de l'amortissement dc l'émission, conformément aux tableaux d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt ct devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lcsditcs obligations seront émises en vertu des règlements suivants: T-191 \u2014 $340,000 \u2014 aqueduc, égouts; T-207 \u2014 $84,000 \u2014 voirie, etc.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 13 avril 1970, à 8 heures du soir, Salle du Poste de Police et Feu, 428, Grande-Côte, Rosemère, comté de Terrebonne, P.Q.Lc conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Rosemère (Comté de Terrebonne), ce 12 mars 1970.Le greffier, Mme Pu.Gardiner.Hotel dc ville, 186, rue Philippe, Rosemère (Comté de Terrebonne), P.Q.Téléphone: 625-2446, code 514.33878-o in the loan procedure as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and for 20-year fixed-term for an amount equal to or less than $216,000.However, should they be issued partly for 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $216,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on May 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the tables of redemption of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: T-191 \u2014 $340,000 \u2014 aqueduct, sewers; T-207 \u2014 $84,000 \u2014 roads, etc.Tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held Monday, April 13, 1970, at 8:00 o'clock p.m., at the Police and Fire Station Hall, 428 Grande-Côte, Rosemère, county of Terrebonne, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest nor any of the tenders.Rosemère (County of Terrebonne), March 12, 1970.Mus.Pu.Gardiner, Town Clerk.Town Hall, 186 Philippe Street, Rosemère (County of Terrebonne), P.Q.Telephone: 625-2446, code 514.33878 Paroisse de Sainte-Anne-de-Varennes Comté de Verchères Avis public est par les présentes donné que des .soumissions cachetées et endossées « Soumissions iwur obligations » seront reçues par le soussigné Fernand Brodeur, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, 100, rue d'Youville, case postale 800, Sainte-Annc-de-Varennes, comté dc Verchères, P.Q., jusqu'à 8.30 heures du soir, mardi, le 14 avril 1970, pour l'achat de $381,500 d'obligations de la paroisse de Sainte-Anne-dc-Varennes, comté de Verchères, datées du 1er mai 1970 et remboursables par séries du 1er mai 1971 nu 1er mai 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à ni supérieur à 9)4%, payable semi-unnucllement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux «l'intérêt peut être le même |wur toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1970.Tableau d'amortissement \u2014- S381,500 \u2014 80 ans Année Capital 1er mai 1971.$ 4,500 1er mai 1972 .5,000 1er mai 1973 .6,000 1er mai 1974 .6,000 1er mai 1975 .7,000 1er mai 1976 .7,000 1er mai 1977 .7,000 1er mai 1978 .9,000 1er mai 1979 .9,000 Parish of Sainte-Anne-de-Varennes County of Verchères Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Fernand Brodeur, Secretary Treasurer, Town Hall, 100 d'Youville Street, Post Office Box 800, Sainte-Anne-dc-Varennes, county of Verchères, P.Q., until 8:30 o'clock p.m., Tuesday, April 14, 1970, for the purchase of an issue of $381,500 of bonds of the parish of Saintc-Anne-de-Varcnnes, county of Verchères, dated May 1, 1970 and redeemable serially May 1, 1971 to May 1, 1990 inclusively, with interest at a rate of not less than 8J4%, nor more than 9H%.payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual amortizations, as shown on the table of redemption of this notice.For adjudication only, interest will be calculated as from May 1, 1970.Table of redemption \u2014 8381,500 \u2014 20 years Year Capital Mav 1, 1971.$ 4,500 Mav 1, 1972.5,000 May 1,1973 .6,000 May 1,1974 .6,000 May 1, 1975 .7,000 May 1,1976 .7,000 May 1,1977.7,000 May 1, 1978 .9,000 May 1,1979 .9,000 2040 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, u° 13 1er mai 1980.S 9,000 May 1, 1980.$ 9,000 1er mai 1981.10,000 May 1, 1981.10,000 1er mai 1982.11,000 May 1, 1982.11,000 1er mai 1983.12,000 May 1, 1983.12,000 1er mai 1984.13,000 May 1, 1984.13,000 1er mai 1985.15,000 Mav 1, 1985.15.000 1er mai 1986.15,000 May 1, 1986.15,000 1er mai 1987.16,000 May 1, 1987.16,000 1er mai 1988.18,000 May 1, 1988.18,000 1er mai 1989 .20,000 May 1, 1989 .20,000 1er mai 1990.182,000 May 1, 1990.182.000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde ù courte échéance 10 ans pour une purtic et l'autre purtic à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans uvec le solde ù courte échéance 5 ans |>our une partie et l'uutre purtic ù terme fixe 20 uns.6° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie ct l'autre purtic A terme fixe 20 ans.Toutefois, dans lc eus des paragraphes 4°, 5° et 6°, les obligations échéant à terme fixe 20 nns ne devront pas être pour un montant inférieur ù $22,000 ct si supérieur à ce dernier montant, cette pnrtic devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant pur les dernières années d'échéances de la partie renouvelable ci-après mentionnée Egalement, les obligations émises ù courte échéance 5 uns ou 10 uns, ne devront comporter que des amortissements annuels entiers, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant lu purtic (pli scru ù terme fixe 20 uns.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément ù la loi.L'échéance du 1er mai 1990 au montant dc $182,000 comprend un solde dc $161,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit : -limée Capital 1er mai 1991.8 12,000 1er mai 1992.12,000 1er mai 1993.13,000 1er mai 1994.14,000 1er mai 1995.15,000 1er mai 1996.16,000 1er mai 1997.18,000 1er mai 1998.19,000 1er mai 1999 .20,000 1er mai 2000 .22,000 L'adjudicataire s'engage ù payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Saintc-Annc-de-Vurenncs.Le capital ct les intérêts sont payables ù toutes les succursales dans la province «le Québec de la banque dont le nom est mentionné dans In procédure d'emprunt.Lcsditcs obligations ne seront pus rachctablcs pur anticipation si elles sont émises par séries ou Moreover, the following terms nnd conditions only shall be considered: 1.Five-year, or 10-year or 15-year short-tern scrinl bonds.2.Ten-yeur serial bonds with the balance us 20-ycar fixed-term bonds.3.Ten-year serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds.4.Ten-year serial bonds with thc balance as 10-year short-term bonds for one part und 20-ycar fixed-term bonds for thc other part.5.Ten-year serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds for one part and 20-ycar fixed-term bonds for the other part.6.Five-year short-term serial bonds for one part and 20-ycar fixed-term bonds for the other part.However, in the case of paragraphs 4, 5 and (i, thc 20-year fixed-term bonds shall be for nu amount of not less than $22,000, and if greater than thc latter amount, said part must comprise only one or more complete annual amortizations, taking into uccount the tables of mal inities appearing in this notice and starting with the last years of maturities in the renewable |iart hereinafter mentioned.Also, 5-ycur or 10-year short-term bonds shall comprise only entire annual amortizations, und starting with the last years of maturities, excluding the 20-year fixed-term part.However, tenders -hall be sent for one of the above methods of issue only, nnd they shall comprise one only of thc terms, save in the case of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The Mav 1, 1990 maturity in the amount of $182,000 includes a balance of $161.000 renewable for an additional ten-ycur period, and maturing as follows: Year Capital May 1, 1991.S 12,000 May 1, 1992.12.000 May 1,1993.13.000 Mav 1,1994.14.000 Mav 1, 1995.15,000 May 1, 1996.16,000 May 1, 1997.18,000 May 1, 1998.19.000 May 1, 1999.20,000 May 1.2000 .22,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any.by certified cheque payable at par at Saintc-Anne-de-Varennes.Capital and interest are payable ul all branche» in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure The said bonds will not be redeemable hy anticipation if they are issued serially »r QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.IS 2041 en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre de $182,000.Toutefois, si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $182,000 les obligations ainsi émises seront rachctablcs par anticipation, au pair, le 1er mai dc chaque année pour le moulant annuel requis pour les fins dc l'amortissement de l'émission, conformément aux tableaux d'échéances dc l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal ù 1% du montant dc l'emprunt ct devra spécifier si lc prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lcsditcs obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 398 \u2014 8272,100 \u2014 aqueduc, cgouls.etc.; 400 \u2014 $6,200 \u2014 voirie; 401 SI 1,1 H!!) \u2014 voirie; 402 \u2014 $2,200 \u2014 voirie; 403 \u2014 §90,001) \u2014 services récréatifs et communautaires.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 14 avril 1970, à 8.30 heures du soir, Hôtel de ville, 100, rue d'Youville, case postale 800, Sainte-Aniic-dc-Vurcnnes, comté de Verchères, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Stc-Anne-de-Varennes (Comté de Verchères), ce 23 mars 1970.Le secrétaire-trésorier, Fernand Brodeur.100.rue d'Youville, case postale 800, Stc-Anne-de-Varennes, Comté île Verchères, P.Q., Téléphone: 652-2888, code 514.33870-o serially and for 20-year fixed-term bonds for an amount equal to or less than $182,000.However, should they be issued partly for 20-year fixed-term bonds for an amount greater than 8182,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on May 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the tables of redemption of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tenders.Thc said bonds will be issued under the following by-laws: 398 \u2014 8272,100 \u2014 aqueduct, sewers, etc.; 400 \u2014 86,200 \u2014 voirie; 401 \u2014 811,000 \u2014 roads; 402 \u2014 82,200 \u2014 roads; 403 \u2014 $90,000 \u2014 recreational and community services.Tenders will be opened and considered at a meeting of thc council to be held Tuesday, April 14, 1970, at 8:30 o'clock p.m., at the Town Hall, 100 d'Youville Street, Post Office Box 800, Suinte-Anne-de-Varenncs, county of Verchères, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Sainte-Anne-de-Varennes (County of Verchères), March 23, 1970.Fernand Brodeur, Secretary Treasurer.Town Hall, 100 d'Youville Street, Sainte-Annc-dc-Varennes, County of Verchères, P.Q., Telephone: 652-2888, code 514.33879 Cité de Hull Comté de Hull Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Roland Stevens, greffier, Hôtel de ville, Hull, comté de Hull, P.Q., jusqu'à 3 heures de l'après-midi, lundi, le 13 avril 1970, pour l'achat de 81.471,000 d'obligations de la cité de Hull, comté de Hull, datées du 1er mai 1970 et rcm-boursablcs par séries du 1er mai 1971 au 1er mai 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inféri eur à 8)4%, n! supérieur a 9)4%, payable scmi-iinuiiellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux «l'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis ù chaque taux dilférenl doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudiciation seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1970.City of Hull County of Hull Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Roland Stevens, Clerk, City Hall, Hull, county of Hull, P.Q., until 3:00 o'clock, p.m., on Monday, April 13, 1970, for the purchase of an issue of 81,471,000 of bonds for the city of Hull, county of Hull, dated May 1, 1970 and redeemable serially from May 1, 1971 to May 1, 1990 inclusively, with interest at a rate not less than 8)4%, nor more than 9)4%, payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for thc whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued ut each different rutc must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from May 1, 1970.Tableau d'amortissement \u2014 $1,471,000 \u2014 20 ans Table of redemption \u2014 S1,471,000 \u2014 20 years Année Capital Year Capital 1er mai 1971.8 45,000 May 1, 1971.$ 45,000 1er mai 1972 .48,000 Mav 1, 1972.48,000 1er mai 1973 .52,000 May 1, 1973.52,000 1er mai 1974 .57,000 May 1, 1974.57,000 1er mai 1975 .58,000 May 1, 1975.58,000 1er mai 1976.65,000 May 1, 1976.65,000 1er mai 1977 .70,000 May 1, 1977.70,000 1er mai 1978 .76,000 May 1, 1978.76,000 1er mai 1979 .81,000 Mav 1, 1979.81,000 1er mai 1980.85,000 May 1, 1980.85,000 1er mai 1981.44,000 May 1, 1981.44,000 1er mai 1982.47,000 Mav 1, 1982.47,000 2042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 88 mars 1970, 108' année, n° 18 1er mai 1983.$ 49,000 1er mai 1984 .53,000 1er mai 1985 .59,000 1er mai 1986 .62,000 1er mai 1987 .69,000 1er moi 1988.-.72,000 1er mai 1989.77,000 1er mai 1990.302,000 May 1, 1983.S 49,000 May 1, 1984.53,000 May 1, 1985.59,000 May 1, 1986 .62,000 May 1, 1987.69,000 May 1, 1988.72,000 May 1, 1989 .77,000 May 1, 1990.302,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec lc solde ù terme fixe 20 ans.3e Obligations échéant en séries 10 uns avec le solde ù courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde ù courte échéance 10 ans pour une partie ct l'autre partie ù ternie fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec lc solde ù courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre purtic ù terme fixe 20 ans.6° Obligations échéunt en séries avec courte échéance 5 uns pour une partie ct l'autre partie ù terme fixe 20 ans.Toutefois, duns le cas des paragraphes 4e, 5° ct 6°, les obligations échéant ù terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur il 830,000 et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent uvis, et en commençant par les dernières années d'échéances de la partie renouvelable ci-après mentionnée.Également, les obligations émises à courte échéance 5 nns ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements annuels entiers ct en commençant par les dernières années d'échéances excluant lu partie qui sera ù terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément ù la loi.L'échéance du 1er mai 1990 au montant dc 8302,000 comprend un solde de 8218,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, ct échéant comme suit: Année Capital 1er mai 1991.$15,000 1er mai 1992.16,000 1er mai 1993.18,000 1er mai 1994.19,000 1er mai 1995 .20,000 1er mai 1996 .22,000 1er mai 1997 .24,000 1er mai 1998 .26,000 1er mai 1999 .28,000 1er mai 2000 .30,000 L'adjudicataire s'engage ù payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair ù Hull.Lc capital et les intérêts sont payables ù toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont lc nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal dc ladite banque ù Toronto ct ù Ottawa, Ontario.Lesditcs obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries ct terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre dc $302,000.Toutefois, si elles sont émises en partie a terme fixe 20 ans pour un Moreover, only the following terms and conditions shall be considered : (1) Five-year, 10-year or 15-ycur short-term serial l>onds.(2) Ten-year serial bonds with the balance as 20-ycar fixed-term bonds.(3) Ten-year seriul bonds with the balance as 5-ycur short-term bonds.(4) Ten-year serial bonds with the balance as 10-year short-term bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other purl.(5) Ten-year serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds for one part und 20-year fixed-term for the other part.(6) Five-year short-term serial bonds for one part und 20-ycar fixed-term bonds for the other part.However, in the case of paragraphs 4.5 and (i.thc bonds maturing as 20-ycar fixed-term should not be for an amount inferior to 830,000, and i! higher than this latter amount, this purl must comprise only one or more entire annual amortisations, bearing in mind thc tables of maturities appearing in this notice, and starting by the lust years of maturities of the renewable part hereinafter mentioned.Also, bonds issued as 5-year or 10-ycar short-term must include only whole annual amortizations, starling by the last years of maturities excluding thc 20-year fixed-term part.However, tenders shall be sent for one ol the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the eases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The Mav 1, 1990 muturitv in the amount of 8302,000 includes a balance of 8218,000 renewable for nn additional 10-ycar period, and maturing as follows: Year ( 'auital May 1.1991.$15.000 Mav 1, 1992.16.000 May 1, 1993.IS.000 Mav 1, 1994.19.000 May 1,1995 .20.000 May 1, 1996.22.001) May 1,1997 .21,000 May 1, 1998.26.000 Mav 1, 1999 .28.0011 May 1,2000 .30,000 Thc successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable ut par at Hull.Capital and interest are payable at all branches in thc Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the head office of thc said bank in Toronto and Ottawa, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they arc issued serially or serially and for 20-year fixed-term, for nn amount equal to or less than $302,000.However, if they are issued partly for 20-ycar fixed-term for QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 2043 niontunl supérieur ù 3302,000 les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er mai de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement dc l'émission, conformément aux tableaux d'échéances 1er mai 1982.S 2,000 May 1, 1982.8 2,000 1er mai 1983.2,000 May 1, 1083 .2,000 1er mai 1984.2,000 May 1, 1984 .2,000 1er mai 1985 .2,500 May 1, 1985 .2,500 1er mai 1986 .2,500 May 1, 1986.2,500 1er mai 1987 .2,500 May 1, 1987.2.500 1er mai 1988 .3,000 May 1, 1988.3.000 1er mai 1989.3,000 May 1, 1989.3.000 1er mai 1990.156,500 May 1, 1990.156.500 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.18 2045 I,'adjudicataire' s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair a L'Annonciation.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales «lans la province «le Québec de la l>an 1970.Le secrétaire-trésorier, F.MILIKX 1 ) i .- u i ; ; :.: Salle municipale, 24, Principale-Sud, C.P.398, L'Annonciation (Labelle), P.Q.Téléphone: 275-2929, code 819.33864-o Paroisse de Sainte-Marie Comté de Beaucc Avis public est pur les présentes donné que îles soumissions cachetées ct endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Benoit Fcclcau, secrétaire-trésorier, jusqu'à 7.30 heures du soir.Bureau «lu secrétaire-trésorier.R.R.No 3, Paroisse dc Stc-Marie, (Beaucc), P.Q., et par après jusqu'à 8 heures «lu soir, Salle paroissiale.Paroisse de Ste-Muric, (Beaucc), P.Q., mercredi, le 15 avril 1970, pour l'achat de $54,000 d'obligations dc la paroisse de Stc-Marie, comté «le Beaucc, datées du 1er mai 1970 et remboursables par séries «lu 1er niai 1971 au 1er mni 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur il 8Jâ%, ni supérieur ù 9^0%, payable semi-aiinuellcmcnt les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Lc taux d'intérêt peut être le même pour toute remission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis ù chaque taux «lifférent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré nu tablcuu d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1970.7oM,ii\u201e d'amortissement \u2014 854,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 1971.$ 500 1er mai 1972.500 1er mai 1973 .500 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at L'Annonciation.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure The said bonds will not be redeemable by anticipation if they arc issued serially or serially and for 20-year fixed-term for an amount cquul to or less than $156,500.However, if they art-issued partly for 20-year fixed-term for an umount higher than $156,500, the bonds so issued will be rcileemablc by unticipntion, nt pur, on May 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the tables of maturities of the issue appearing in the notice Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 172 \u2014 $189,000 \u2014 aqueduct, sewers.Thc tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Thursday, April 16, 1970, at 8:00 o'clock, p.m., at the Municipal Hall, 24 Principal South, Post Office Box 398, L'Annonciation, County of Labelle, The council does not bind itself to ucccpt the highest or any of the tenders.L'Annonciation (County of Labelle), March 18, 1970.I-'.MII.ii.n I >] .-I.A t ' hi 1 .us, Secretary-Treasurer.Municipal Hull, 24 Principal South, P.O.Box 398, L'Annonciation (Labelle), P.Q.Telephone : 275-2929, eoile 819.33864 I'.iri-li of Sa in I.-Marie County of Beauce Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Benoit Fectcau, Secretary-Treasurer, until 7:30 o'clock, p.m., at the Office of the Secretary-Treasurer, R.R.No.3, Parish of Stc-Marie, (Beaucc), P.Q., and after until 8:00 o'clock, p.m., at the Parish Hall, Parish of Stc-Marie, (Beauce), P.Q., on Wednesday, April 15, 1970, for the purchase of an issue of $54,000 of bonds for the Parish of Stc-Marie, County of Beauce, dated May 1.1970 and redeemable serially from May 1, 1971 to May 1, 1990 inclusively, with interest at a rate not less than 8^2%, nor more thnn 9)->%, payable semiannually on May 1st und November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rnte must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from May 1, 1970.Table of redemption Year May 1, 1971.May 1, 1972.May 1, 1973.\u2014 854,000 \u2014 20 years Capital .% 500 .500 .500 2040 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 13 1er mai 1974.$ 500 1er mai 1975.500 1er mai 1976 .500 1er mai 1977 .500 1er mai 1978 .500 1er mai 1979.500 1er mai 1980.500 1er mai 1981.500 1er mai 1982 .500 1er mai 1983.500 1er mai 1984 .500 1er mai 1985 .500 1er mai 1986.500 1er mai 1987 .500 1er mai 1988.1,000 1er mai 1989.1,000 1er mai 1990 .43,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 nns avec le solde ù courte échéance 10 ans pour une partie ct l'autre partie ik terme fixe 20 nns.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.6° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie ct l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5e et 6°, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 84,000, et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dnns le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances dc la partie renouvelable ci-nprès mentionnée Également, les obligations émises ù courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements annuels entiers, ct en commençant par les dernières années d'échéances excluant la partie qui sera ii terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er mai 1990 au montant de 843,500, comprend un solde dc $42,500, renouvelable pour une période additionnelle dc 20 ans, ct échéant comme suit: /limée Capital 1er mai 1991.$ 1,000 1er mai 1992.1,000 1er mai 1993.1,000 1er mai 1994.1,000 1er mai 1995.1,500 1er mai 1996.1,500 1er mai 1997.1,500 1er mai 1998.1,500 1er mai 1999 .2,000 1er mai 2000.2,000 1er mai 2001.2,000 1er mai 2002 .2,000 1er mai 2003.2,500 1er mai 2004 .2,500 1er mai 2005 .2,500 May 1, 1974.$ 500 May 1, 1975 .500 May 1, 1976.500 May 1, 1977.500 May 1, 1978.500 May 1, 1979.¦ 500 May 1, 1980.500 May 1, 1981.500 May 1, 1982.500 May 1, 1983.500 May 1, 1984.500 May 1, 1985.500 May 1, 1986 .500 May 1, 1987 .500 May 1, 1988.1,000 May 1, 1989.1,000 May 1, 1990 .43,500 Moreover, thc following terms and conditions only shall be considered.(1) Five-year, 10-ycar or 15-year short-ten serial bonds.(2) Ten-year serial bonds with thc balance as 20-ycar fixed-term bonds; (3) Ten-year serial bonds with the balance as 5-ycar short-term bonds; (4) Ten-year serial bonds with thc balance as 10-ycar short-term bonds for one part and 20-ycar fixed-term for thc other part; (5) Ten-year serial bonds with the balance as 5-ycar short-term bonds for one part and 20-ycar fixed-term bonds for the other part ; (6) Five-year short-term bonds for one |iart and 20-ycar fixed-term bonds for the other part.However, as far as paragraphs (4), (5) and (6) arc concerned, the 20-year fixed-term bonils should be for an amount of not less than 84,000.and if greater than the latter amount, the said purt should include one only or several complete annual amortizations, bearing in mind I lie table of maturities appearing in this notice and starting by the last years of maturities of the renewable part hereinafter mentioned.Also, the 5-ycar or 10-ycar short-term bonds shall include complete annual amortizntions only, und starling with thc lust years of maturities, excluding the 20-year fixed-term part.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in in the cases of thc exceptions stipulated above.Adjudication shall be made according to law.Thc May 1, 1990 maturity in the amount of $43,500 includes a balance of 842,500 renewable for an additional 20-year period, and maturing as follows: Year Capital May 1, 1991.S 1.000 May 1,1992.1,000 May 1, 1993.1.000 May 1,1994.1.000 May 1,1995.1,500 May 1, 1996.1,500 May 1,1997.1.500 May 1, 1998.1,500 May 1, 1999.2.000 May 1,2000 .2.000 May 1,2001.2,000 May 1,2002 .2,000 May 1,2003 .2,500 May 1,2004 .2.500 May 1,2005.2,500 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 2047 1er moi 2006.S 3,000 1er mai 2007 .3,000 1er mai 2008.3,500 1er moi 2009.3,500 1er mai 2010.'.4,000 I, adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital ct intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Ste-Maric.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec dc la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.I.e-dites obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égul OU moindre de $43,500.Toutefois, si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $43,500, les obligations ainsi émises seront rachctablcs par anticipation, au pair, le 1er mai dc chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément aux tableaux d'échéances dc l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt ct devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Lcsditcs obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 34-B \u2014 $54,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue à 8 heures du soir, mercredi, le 15 avril 1970, à la Salle paroissiale.Paroisse de Ste-Maric, comté de Beaucc, P.Q.Le conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Sainte-Marie (Comté dc Hcauce), ce 19 mars 1970.Le secr&aire-lrisorier, Benoit Fkcteau.Bureau du secrétaire-trésorier, R.R.No 3, Paroisse dc Sainte-Marie, Comté dc Beauce, P.Q.Téléphone: 387-6140, code 41S.33880-o Cite de Saint-Jérôme Comté dc Terrebonne Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions |k>nr obligations » seront reçues par le soussigné Gérard Maurice, greffier, Hôtel «le ville, 280, rue Labelle, St-.Iérôme, comté de Terrebonne, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mercredi, lc 15 avril 1970, pour l'achat de $1,401,000 d'obligations dc lu cité île St-Jérômc, comté dc Terrebonne, datées du 1er mai 1970 ct remboursables par séries du 1er mai 1971 au 1er mai 1990 inclusivement avec intérêt ù un taux non inférieur à 814%, ni supérieur à 9J4%, payable scmi-annucllement les 1er mai ct 1er novembre dc chaque année.Le 'oux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilise, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels une montrés au tableau d'amortissement dans le présent avis.Règlements Nos: C-557 \u2014 $129,000 \u2014 bâtisses, terrains, etc.; C-567 \u2014 $270,300 \u2014 coût excédentaire de divers règlements; C-568 \u2014 $150,000 \u2014 JJ»ric; C-577 \u2014 $70,000 \u2014 aqueduc, égouts, etc.; I -578 $50,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie, etc.; May 1, 2006.$ 3,000 May 1,2007.3,000 May 1,2008 .3,500 May 1,2009 .3,500 May 1, 2010 .4,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Ste-Marie.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and for 20-year fixed-term for an amount equal to or less than $43,500.However, if they are issued partly for 20-year fixed-term for an amount higher than $43,500, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on May 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the tables of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be uccompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 34-B \u2014 354,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads.Thc tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held at 8:00 o'clock, p.m., on Wednesday, April 15, 1970, at the Parish Hall, Parish of Ste-Maric, county of Beauce, P.Q.The council does not bind itself to accept thc highest or any of thc tenders.Sainte-Marie (County of Beaucc), March 19, 1970.Benoit Fecteau, Secretary-Treasurer.Office of the Secretary-Treasurer, R.R.No.3, Parish of Sainte-Marie, County of Beaucc, P.Q.Telephone : 387-6140, code 4 IS.33880 City of Saint-Jérôme County of Terrebonne Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for bonds\" will l>c received by the undersigned, Gérard Maurice, City Clerk, City Hall, 280 Labelle Street, St-JérÔmc, county of Terrebonne, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., Wednesday, April 15, 1970, for the purchase of an issue of $1,401,000 of bonds for the city of St-Jérôme, county of Terrebonne, dated May 1, 1970, and redeemable serially from May 1, 1971 to May 1, 1990 inclusively, with interest at a rate not less than 83.-2%, nor more thun 9}-2%> payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be thc same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rute must cover one or more entire annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.By-laws Nos.C-557 \u2014 $129,000 \u2014 buildings, lands, etc.; C-567 \u2014 $270,300 \u2014 excess cost of various by-laws; C-568 \u2014 $150,000 \u2014 ronds; C-577 \u2014 $70,000 \u2014 aqueduct, sewers, etc.; C-578 \u2014 $50,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads, etc.; 2048 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' aimée, n\" 18 C-579 \u2014 $165,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie, etc.; C-582 \u2014 $16,500 \u2014 achat d'équipement pour le service d'incendies; C-584 \u2014 $57,500 \u2014 aqueduc, égouts; C-585 \u2014 $26,500 \u2014 voirie; C-586 \u2014 $21,000 \u2014 voirie; C-587 \u2014 $40,500 \u2014 expropriation dc lots; C-591 \u2014 $90,000 \u2014 voirie; \u2014 C-592 \u2014 $25,000 \u2014 service récréatif ct communautaire ; C-593 \u2014 $67,500 \u2014 voirie; C-594 \u2014 $73,500 \u2014 achat d'équipement; C-599 \u2014 $13,000 \u2014 coût excédentaire du règlement No C-537; C-601 \u2014 $5,200 \u2014 bâtisses et terrains; C-603 \u2014 $42,000 \u2014 aquoluc, égouts, voirie, etc.; C-604 \u2014 $13,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie, etc.; C-606 \u2014 $31,500 \u2014 aqueduc, égouts; C-607 \u2014 $30,000 \u2014 voirie, bft-tisscs, terrains, tec.; C-608 \u2014 $14,000 \u2014 achat d'équipement pour lc service d'incendies.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1970.Tableau d'amortissement \u2014 SI ,1,01,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 1971.$ 63,000 1er mai 1972 .68,000 1er mai 1973 .73,000 1er mai 1974 .79,000 1er mai 1975.85,000 1er mai 1976 .75,000 1er mai 1977 .80,000 1er mai 1978.87,000 1er mai 1979 .94,000 1er mai 1980.102,000 1er mai 1981.41,000 1er mai 1982 .44,000 1er mai 1983 .48,000 1er mai 1984 .52,000 1er mai 1985 .56,000 1er mai 1986 .60,000 1er mai 1987 .65,000 1er mai 1988.71,000 1er mai 1989 .76,000 1er mai 1990.82,000 Kn plus, les modalités suivantes seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde ù terme fixe 20 ans.3e Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec lc solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie ù terme fixe 20 ans.6° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5° ct 6°, les obligations échéant ii terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur ù $82,000, et si supérieur ù ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans lc présent avis, ct en commençant par les dernières années d'échéances.Également, les obligations émises A courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements annuels entiers, ct en commençant par les dernières années d'échéances excluant la partie qui sera à terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des C-579 \u2014 $165,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads, etc.; C-582 \u2014 $16,500 \u2014 purchase of equipment for the fire department; C-584 \u2014 $57,500 \u2014 aqueduct, sewers; C-585 \u2014 $26,500 \u2014 roads' C-586 \u2014 $21,000 \u2014 roads; C-587 \u2014 $40,500 \u2014 expropriation of lots; C-591 \u2014 $90,000 \u2014 roads; C-592 \u2014 $25,000 \u2014 recreational and community services; C-593 \u2014 $67,500 \u2014 roads; C-594 \u2014 $73,500 \u2014 purchase of equipment; (.'-599 \u2014 $13,000 \u2014 excess cost of by-law No.C-537: C-601 \u2014 $5,200 \u2014 buildings and lands; C-603 -' $42,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads, etc.; C-604 \u2014 $13,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads, etc.; C-606 \u2014 $31,500 \u2014 aqueduct, swers; C-607 \u2014 $30,000 -roads, buildings, lands, etc.; C-608 \u2014 S14.000 \u2014 purchase of equipment for the fire depart ment.For adjudication only, interest will be calculated as from May 1, 1970.Table of redemption \u2014 81,401,000 \u2014 20 years Year Capital May 1, 1971.$ 63,000 May 1, 1972 .68,000 May 1, 1973.73,000 May 1, 1974 .79,000 May 1, 1975 .85,000 May 1, 1976.75,01X1 May 1,1977 .80,000 May 1, 1978.87,000 May 1, 1979 .94,000 May 1, 1980.102,000 May 1,1981.41,000 May 1,1982.44,000 May 1, 1983.48,000 May 1, 1984 .52,000 May 1, 1985 .56,000 May 1, 1986 .60,000 May 1, 1987.65,000 May 1, 1988.71,000 May 1, 1989 .76,000 May 1, 1990.82,000 Moreover, only the following methods shall lie considered : (1) Five-year, 10-ycar or 15-ycar short-term serial bonds.(2) Ten-year serial bonds with the balance fur 20-year fixed-term.(3) Ten-year serial bonds with the balance fur 5-yenr short-term.(4) Ten-year serial bonds with the balance partly for 10-yenr short-term nnd partly for 20-ycur fixed-term.(5) Ten-year serial bonds with the balance purtly for 5-ycnr short-term and partly for 20-year fixed-term.(6) Five-year short-term serial bonds for the one part and 20-year fixed-term for the other purt.However, in the case of paragraphs 4, 5 and 6, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than $82,000, and, if higher than this latter amount, the said part shall comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the table of maturities appenring in this notice, and starting by thc last years of maturities.Also, 5-ycar or 10-ycar short-term bonds shall comprise only entire annual amortizations, starting by the last years of maturities und excluding the 20-ycar fixed-term part.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of thc terms, save in thc cases of the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 2049 ternies sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Jérôme.I,e capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la lianque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lcsditcs obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre de $82,000.Toutefois, si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur ù $82,000, les obligations ainsi émises seront rachctablcs par anticipation, au pair, le 1er mai de chaque année pour lc montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt ct devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment «le leur livraison.Ix-s soumissions seront ouvertes ct considérées à une séance «lu conseil qui sera tenue, mercredi, le 15 avril 1970, n 8 heures du soir, Hôtel «le ville, 280, rue Labelle, St-Jérôme, comté de Terre-lionne, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'ucccptcr ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Jérôme (Comte de Terrelionnc), ce 19 mars 1970.Le greffier, gérard Maurice.Hotel de ville.280, rue Labelle, St-.Iérômc (Terrebonne), P.Q.Téléphone: 435-6881.436-1511, code 514.33881-0 exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at St-Jérôme.Capital and interest are payable at all branches in thc Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they arc issued serially or serially and for 20-year fixed-term for an amount equal to or less than $82,000.However, if they arc issued partly for 20-ycar fixed-term for an amount greater than $82,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on May 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities of thc issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, an«l must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.Thc tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Wednesday, April 15, 1970.at 8:00 o'clock p.m., in the City Hall, 280 Labelle Street, St-Jérôme, county of Terrebonne, P.Q.The council docs not bind itself to accept thc highest or any of the tenders.Saint-Jérôme (County of Terrebonne), March 19, 1970.Gérard Maurice, City Clerk.City Hall, 280 Labelle Street, St-Jérôme (Terrebonne), P.Q.Telephone: 435-6881, 436-1511, coile 514.33881 Regie des M arches Agricoles du Québec Modifications au plan conjoint des producteurs de Imms de pulpe dc Rimouski-.Matapédia Prenez avis que l'offiœ des producteurs de bois de Rimouski, corps politique lc-galemcnt constitué sous l'empire «le la Loi des marchés agricoles «lu Québec et ayant son siège social a Rimouski, cliargé de l'application du plan conjoint des producteurs dc liois «le pulpe «le Rimouski-Mata-pedin, a déposé à la Régie des marchés ugricolcs une requête pour soumettre au référendum des producteurs intéressés des amendements au plan conjoint précité.L'Office requérant recherche divers pouvoirs additionnels prévus ù la Loi, ct demande en plus que la juridiction «lu plan soit modifiée tel qu'indiqué ci-nprès: a) Les 9ième ct ÎOièmc paragraphes du plan conjoint se lisent présentement comme suit: « Le plan conjoint, dont l'application, l'administration et la conduite sont confiées à l'office des producteurs de bois de pulpe «le Rimouski-Matapéilia régira tous les cultivateurs ct les propriétaires de lots ù bois, protluctcurs «le cinq cordes ou plus de bois de pulpe «le la région de Rimouski-Matapédia, fournisseurs aux compagnies forestières de In province dc Québec et tous autres acheteurs faisant affaires dans ladite région.Aux fins des présentes, lu région de Riinouski-\u2022Matupédiu comprend les paroisses de: Québec Agricultural Marketing Board Amendments to the joint plan of pulpwood producers of H i nn i u.-L i - M il t a ped in Take note tliat the \"Office «les producteurs de bois dc Rimouski\", body politic legally constituted under the Québec Agricultural Marketing Act and having its head office in Rimouski, charged with application of the joint plan of pulpwood producers of Rimouski-Matapcdia, has filed with the Agricultural Marketing Board a petition to submit to a referendum of interested producers, amendments to the aforementioned joint plan.The pel it inning Bureau is seeking various additional powers contemplated in the Act, nnd asks, moreover, that jurisdiction of the plan lie amended as indicated hereinafter: (a) The 9th and 10th paragraphs of the joint plan now read as follows: \"The joint plan, the application, administration and direction of which arc entrusted to the \"office des producteurs «le bois de pulpe «le Rimouski-Matapcdia\", shall govern all farmers und proprietors of wooded lots, producers of five cords or more of pulpwood in the Rimouski-Matapcdia region, suppliers to forestry companies in the Province of Québec und all other buyers operating in the sniil region.For these presents, the Rimouski-Mata|>é Pour être vendu au bureau d'enregistrement i«m '''vision de Huntingdon, ù Huntingdon, le TRENTIÈME jour d'AVRIL 1970, ,\\ DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.-LuciKN Primeau.Salaberry de Valleyfield, ce 17e jour de mars 1970.33867-o De Terris District of Beauharnois Superior Court, f P L A Y F AIR INVEST- No.11.054.\\ a MENT & FINANCE ' INC., body politic incorporate in conformity with thc law and having its principal place of business in the city and district of Montreal, Province of Québec, plaintiff, vs MRS.MARY ROSS, unremarried widow of the late Archibald Hcmilton Wright, residing in the village of Hemmingford, or in the surrounding vicinity, district of Beauharnois, Province of Québec, and MRS.DOROTHY WRIGHT, wife separate as to property of of James George Thompson, residing and domiciled at the same place, and JAMES GEORGE THOMPSON, farmer of the same place, defendants.\"A farm situated in the parish of Hemmingford, county of Huntingdon, known and designated as being lot number one hundred and eighty B (180 B) on the official plan and book of reference on the granted lands of thc township of Hemmingford, having an area of fifty-two acres, two \"rods\" and twenty-two rods, English measure and more or less.With a house and another building erected thereon, fronting on thc public road known as being Williams Road.\" To be sold at the registry office of thc division of Huntingdon, at Huntingdon, on the THIRTIETH day of APRIL, 1970, at TEN o'clock in the morning.J.-Lucies Prim eau, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Salaberry de Valleyfield, March 17, 1970.33867 2058 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 38 mars 1970, 102' année, n\" 13 De Terris District île Beauharnois Cour Supérieure, ( A LCIDE LALONDE, con-No 11,031.\\ tracteur domicilié et ' résidant ù Rivière Beaudette, district de Beauharnois, demandeur, contre HENRI LARIVIÈRE, de Glen Robertson, province d'Ontario, mais ayant propriété à Rivière Beaudette, district dc Beauharnois, défendeur et ALBERT FARAND, en sa qualité dc registratcur de la division d'enregistrement de Soulanges, de Coteau Landing, district dc Beauharnois, mis en cause.« Un certain emplacement situé en la municipalité de la paroisse dc Stc-Clairc d'Assise de Rivière Beaudette dans le comté dc Soulanges, étant partir dudit lot numéro huit cent trente (Pi No 830) des plan ct livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Zotique, division d'enregistrement de Soulanges, mesurant cinquante pieds (50') de largeur sur cent quatre-vingts pieds (180') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, et l)orné comme suit: En front vers l'ouest par le chemin public, vers le sud par un certain emplacement vendu à Gilbert Lalondc étant partie dudit lot, vers lc nord et en urrière vers l'est par le résidu dudit lot 830 appartenant à Alcidc Lalondc, la ligne sud dudit emplacement étant ù environ 175 pieds de la ligne separative des lots numéros 829 et 830, avec maison et dépendance dessus érigées.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement dc la division dc Soulanges à Coteau-Landing, le VINGT-NEUVIÈME jour d'AVRIL 1970, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.-LUCIEN PniUEAU.Salaberry dc Valleyfield, ce 17e jour dc mars 1970.33866-0 GASPÉ De Terris District of Beauharnois Superior Court, ( A LCIDE LALONDE, eon-No.11,031.\\ ¦** tractor domiciled and I residing at Beaudette River, district of Beauharnois, plaintiff, M HENRI LARIVIÈRE, of Glen Robertson, Province of Ontario, but having property of Beaudette River, district of Beauharnois, defendant, and ALBERT FARAND, in his capacity us registrar for the registration division of Soulanges, Coteau Landing, district of Beauharnois, mis en cause.\"A certain emplacement situated in tlic municipality of the parish of Stc-Clairc d'Assise of Beaudette River in the county of Soulanges, being part of said lot number eight hundred and thirty (Pt No.830) on the official plan and book of reference of the parish of St-Zotique, registration division of Soulanges, measuring fifty feet (50') in width by one hundred and eighty feet (180') in depth, English measure and more or less, and bounded as follows: In front on the west by the public road, on the south by a certain emplacement sold to Gilbert Lalonde being part of the said lot, on the north and in the rear on thc east by thc remainder of snid lot 830 belonging to Alcidc Lalondc.the south line of thc said emplacement being ut about 175 feet from the separative line of lots numbers 829 and 830, with a house and dejicndciicics erected thereon.\" To l>e sold at the registry office of thc division of Soulanges, at < 'otcau-Landing, on the TWENTY-NINTH day of APRIL, 1970, at TEX o'clock in the morning.J.-Lucibn pnimkal\".Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Salabcrrv dc Vallevfield, this 17th day of March, 1970.33868 GASPÉ Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Gaspé Cour Provinciale, J pOMUALD PAQUET, No.8228.\\ -tv demandeur, versus t ALEXANDRE SAVARD, défendeur.« Un immeuble sis et situé en In pnroissc de Stc-Anne des Monts, consistant en un terrain déforme irrégulière, mesurant de est en ouest, une largeur dc 80' par une profondeur dc nord au sud dc 86', mesure anglaise, uvec bâtisses désignées comme faisant partie du lot portant le numéro 42 subdivision 7 (ptic 42-a-7) des plans et livres de renvoi du cadastre officiel pour le premier rang du Fief Stc-Anne des Monts Notre-Dame et borne comme suit: au nord-ouest, par une autre partie du lot 42-a-7 dc Jean-Marc Paquet; au nord-est par le lot 42-a-2 de Mme Adrien Simurd; au sud-est partie pur lc lot 42-a-6 dc Thomas Fournier et pnrtic par une autre partie par le lot 42-te-7 dc Aurclc Dugas et au sud-ouest par une ruelle.« Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Ste-Anne des Monts, situé au Paluis dc Justice dc Ste-Anne des Monts, VENDREDI, le HUITIÈME jour dc MAI 1970, ù DIX heures de l'avant-midi.Le shérif intérimaire.Bureau du Shérif, Jean Bourget.Percé, le 18 mars 1970.33870-O Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Gaspé Provincial Court, ( p OMUALD PAQUET.No.8228.\\ plaintiff; versu» l ALEXANDRE SAVARD.défendant.\"An immovable situated and located in the parish of Sain te-Anne des Monts, consisting in a piece of land of irregular figure, measuring from east to west a width of 80' by n depth from north to south of 86', English measure, with buildings designated as being purl of tlic lot bearing number 42, subdivision 7 (P.42-a-7l on thc plans and books of reference of the official cadastre for thc first range of the Fief Suinte-Anne des Monts Notre-Dame and bounded as follows: on the northwest by another part of lot 42-a-7 of Jean-Marc Paquet; on tlic northeast by lot 42-a-2 of Mrs.Adrien Simurd; ou the southeast partly by lot 42-u-6 of Thomas Fournier and partly by another part of lot 42-a-i of Aurèle Dugas and on the southwest by a lane.\" To be sold at the Sainte-Anne «les Monts registry office, situated at the Sainte-Anne des Monts Court House, on FRIDAY, the EIGHTH day of MAY, 1970, at TEN o'clock in the forenoon.Jean Bourget, Sheriff's Office, Acting Sheriff.Percé, March 18, 1970.^«0 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 2059 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Gaspé Cour Supérieure, ( /BAISSE POPULAIRE No 34-615.\\ w DE STE-ANNE DES l MONTS, demanderesse, vs DAME ISABELLE TREPANIER LÉVESQUE, Stc-Anne des Monts, comté dc Gaspé Nord, P.Q-, défenderesse.« Lot (42-2), bloc A, premier rang, canton de Tourelle, ayant une superficie de 5,750 pieds carrés, ct mesurant 50 x 115 avec btttisses dessus construites, circonstances ct dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Stc-Anne des Monts, au Palais dc Justice dc Ste-Anne des Monts, VENDREDI, lc HUITIÈME jour de MAI 1970, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif intérimaire.Bureau du Shérif, Jean Bourget.Percé, le 18 mars 1970.33868-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province dc Québec District de Gaspé Cour Provinciale, ( T A CORPORATION MU-No 1496.\\ *-> NICIPALE DE PER-' CÉ, demanderesse, vs LES HÉRITIERS DE FEU AUSTIN HARPER, défendeurs.« Un eerlain morceau de terrain sis et situé dans la municipalité de Percé, connu ct désigné aux plan et livre de renvoi officiels pour ladite municipalité, comme étant les lots no.323, 324 et 325 du canton dc Percé, borne au nord par lc trait carré; à l'est par la propriété de Rodolphe Langlois; au sud par le Golfe St-Laurcnt et à l'ouest par la propriété de Théodore Mathieu, avec bâtisses dessus construites, circonstances ct dépendances, moins un emplacement appartenant ù Lucien Robin, mesurant 300 pieds dc largeur par 300 pieds de profondeur, plus ou moins, borné au nord par la route nationale No 6; ii l'est par la propriété de feu Austin Harper; au sud par lc Golfe St-Laurcnt ct il l'ouest par la propriété de Théodore Mathieu.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Percé, situé au Palais de Justice de Percé, VENDREDI, le HUITIÈME jour de MAI 1970, ù DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint, bureau du Shérif, william Keigiian.Percé, le 18 mars 1970.33869-o H A U T E RI V E Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Gaspé .'Superior Court, ( /\"\"IAISSE POPULAIRE No.34-615.\\ V* DE STE-ANNE DES l MONTS, plaintiff, vs DAME ISABELLE TREPANIER LÉVESQUE, Ste-Anne des Monts, county of Gaspé North, P.Q., defendant.\"Lot 42-2, block A, range one, township of Tourelle, having an area of 5,750 square feet, and measuring 50 x 115, with buildings constructed thereon, circumstances and dependencies.\" To be sold in the Ste-Anne des Monts registry office, in the Court House at Stc-Anne des Monts, on FRIDAY, the EIGHTH day of MAY, 1970, at TEN o'clock in the forenoon.Jean Bouhget, Sheriff's Office, Acting Sheriff.Percé, March 18, 1970.33868 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Gaspé Provincial Court, t THE MUNICIPAL COR-No.1496.\\ 1 PORATION OF PER-l CÉ, plaintiff, vs THE HEIRS OF THE LATE AUSTIN HARPER, defendants.\"A certain piece of land lying and situated in the municipality of Percé, known and designated on thc official plan and in thc book of reference for thc said municipality as being lots numbers 323, 324 and 325 in the township of Percé, bounded on the north by the \"trait carré\"; ¦on the east by the property of Rodolphe Langlois; on thc south by thc Gulf of St.Lawrence, and on the west by thc property of Théodore Mathieu, with the buildings constructed thereon, circumstances and dependencies, less an emplacement belonging to Lucien Robin, measuring 300 fect in width by 300 fect in depth, more or less, bounded on the north by National Highway No.6; on thc cast by the property of thc late Austin Harper; on the south by thc Gulf of St.Lawrence, and on the west by the property ¦of Théodore Mathieu.\" To be sold in the Percé registry office, situated in the Court House at Percé, FRIDAY, the EIGHTH day of MAY, 1970, at TEN o'clock in the forenoon.William Keigiian, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Percé, March 18, 1970.33869 HAUTERIVE De Terris Province de Quebec \u2014 District dc Hauterive Cour Provinciale, ( \\ 71LLE DE PORT-CAR- No S-4745.-j v TIER, corps politique v suivant la Loi de la province de Québec, demanderesse, ts MUNICIPAL MORTGAGE CORP., corps politique dûment constitué, ayant son siège social il 1175 Jeun Talon Est, Montréal, défenderesse.Bloc: 1-49 Babel \u2014 description prise au livre de renvoi officiel.De figure irrégulière, étant une partie du bloc 1, borné au nord-est par lc bloc 1-48; vers le sud-est par une partie du bloc 1-65; vers le sud-ouest par le bloc 1-50, vers le nord- Dc Terris Province of Québec \u2014 District of Hauterive Provincial Court, ^-TOWN OF PORT-CAR-Nô.S-4745.< J- TIER, body politic I according to the Statutes of the Province of Quebec, plaintiff, versus MUNICIPAL MORTGAGE CORP., body politic duly incorporated, having its head office ut 1175 Jean Tulon East, Montreal, defendant.Block : 1-49 Babel \u2014 description taken from tlic official book of reference.Of irregular figure, being a part of block 1, bounded on the northeast by block 1-48; towards the southeast by a part of block 1-65; towards the southwest by block 1-50. 2060 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 13 ouest par une partie du bloc 1-44 (rue); mesurant cent trente-cinq pieds et soixante-quatre centièmes (135.64) sur le côté nord-est, soixante-dix pieds et quatre-vingt-dix-huit centièmes (70.98) le long d'une ligne brisée sur le côté sud-est, cent dix-neuf pieds ct vingt-quatre centièmes (119.24) sur le côté sud-ouest, cent onze pieds et trente-huit centièmes (111.38) sur le côté nord-ouest; contenant en superficie onze mille trois cent dix pieds carrés, mesure anglaise (11,310).Avec bâtisses dessus construites, circonstance et dé|)endance.s.Pour être vendu au bureau d'enregistrement, Palais de Justice Baic-Comcau, le PREMIER jour de MAI 1970, à DEUX heures de l'après-midi.Le shérif adjoint.Daté à Sept-Ilcs, Jean Truciion.le 18 mars 1970.33871-0 De Terris Canada \u2014 Province dc Québec District dc Hautcrivc Cour Provinciale, t T ES COMMISSAIRES No 6356.< D'ÉCOLE pour la mu-' nicipalité scolaire dc Chûtes aux Outardes, corps politique dûment incorporé, ayant place d'affaires à Chûte-aux-Outardes, district dc Hautcrivc, demandeurs, contre CLÉMENT DESBIENS, résidant ct domicilié à Chûtc-aux-Outardes, district dc Hautcrivc, défendeur.Lc lot numéro un-dix-neuf, rang deux, (1-19, rg.2) aux plan et livre dc renvoi du cadastre officiel, pour le canton dc Ragueneau, avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances ct dépendances.Pour être vendu au bureau du régistrateur dc la première division d'enregistrement du comté de Saguenay, au Palais de Justice de Baie Comeau, MERCREDI, le VINGT-NEUVIÈME jour du mois d'AVRIL 1970, ù DIX heures dc l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Marcel Rodrigue.Baie Comeau, le 28 murs 1970.33873-o De Terris Canada \u2014 Province dc Québec District de Hautcrivc Cour Provinciale, j PT,HIBEAULT AUTOS No 4947.\\ *¦ INC., corps politique ' dûment incorporé avec place d'affaires à Hautcrivc, P.Q., demandeur, contre EDDY SAVARD, résidant ct domicilié à Pointe-Lcbcl, comté de Saguenay, P.Q., défendeur.Une maison située sur le lot 57-215, rang 5, canton Manicouagan, ci-dessous désignée.De figure irrégulière borné au nord-est par une partie non subdivisée du lot 57, au sud-est par le lot 57-216, au sud-ouest par un chemin public, au nord-ouest par le lot 57-214, mesurant trois chaincs et soixante-dix mailles au sud-est et au nord-ouest, une chainc et soixante-dix mailles au sud-ouest.Contenant en superficie: .629 acres.Pour être vendu au bureau du régistrateur dc la première division d'enregistrement du comté de Saguenay, au Palais de Justice de Baie-Comeau, JEUDI, le TRENTIÈME jour du mois d'AVRIL 1970, ù DIX heures dc l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Pulais de Justice, Marcel Rodrigue.Baie Comeau, le 28 mars 1970.33874-o towards thc northwest by a part of block 1-44 (street); measuring one hundred and thirty, five feet and sixty-four hundredths 035.64) on the northeast side, seventy fect and ninetv-cight hundredths (70.98) along a broken line on the southeast side, one hundred and nineteen feet and twenty-four hundredths (119.24) on the southwest side, one hundred and eleven feet and thirty-eight hundredths (111.38) on thc north-west side; having an area of eleven thousand three hundred and ten square fect, English measure (11,310).With buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the registry office, at the Haie Comeau Court House, on thc FIRST dav of MAY, 1970, at TWO o'clock in thc afternoon.Jean Truciion, Dated at Sept-Ilcs, Assistant Sheriff.March 18, 1970.3871 De Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Hautcrivc Provincial Court, ( rTHE SCHOOL COMMIS-No.6356.i A SIONERS for the school ^ municipality of Chûtes aux Outardes, body politic duly incorporated, having a place of business at Chûtc-anx-Oiitnrdcs, district of Hauterive, plaintiffs, against CLEMENT DESBIENS, residing and domiciled ul Chute-aux-Oiitardcs, district of Hauterive, defendant.Lot number one-ninetccn, rungc two (1-19, r.2), on thc plnn nnd in the book of reference for the official cadastre of the township of Huguc-ncau, with all the buildings constructed I hereon, circumstances and dependencies.To l)e sold in the office of the registrar for the first registration division of thc county of Saguenay, in thc Court House at Baic Comeau, on WEDNESDAY, the TWENTY-NINTH .lay of the month of APRIL, 1970.at TEN o'clock in thc forenoon.Marcel Rodrigue, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Buic Comeau, March 28, 1970.33873 De Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Hauterive Provincial Court, ( THIBEAULT AUTOS No.4947.j -I INC., body politic duly ' incorporated, with n place o( business nt Hauterive, P.Q., plaintiff, rerm EDDY SAVARD, residing und domiciled at Pointc-I.cbel, county of Saguenay, P.Q., defendant.A house situated on lot 57-215, range 5.township of Manicouagan, hereinafter designated.Of irregular shape, bounded on thc northeast by an unsulxlivided part of lot 57, on thc southeast by lot 57-216, on thc southwest by a public road, on the northwest by lot 57-214, measuring three chains and seventy links on the sou I beast nnd northwest, one chain and seventy links on the southwest, and having an nrcu of .629 of nn acre.To be sold in the office of the registrar for the first registration division of the county of Saguenay, in the Court House at Baic Comeau; on THURSDAY, the THIRTIETH day \"f H* month of APRIL, 1970, at TEN o'clock in tlic forenoon.Sheriff's Office, Marcel RodriuUK, Court House, Assistant Sheriff.Baie Comeau, March 28, 1970.33874 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 2061 De Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Hauterive Cour Supérieure,/ QCTAVE TREMBLAY, No 5932.\\ v-' menuisier, domicilié et ' résidant à St-Paul du Nord, district dc Hauterive, demandeur, contre VICTOR TREMBLAY, menuisier, domicilié et résidant ù St-Paul du Nord, district de Hauterive, défendeur.Un lot de terre situé à Sault-au-Mouton, mesurant soixante pieds (60') en profondeur et une largeur de cent pieds (100') mesurée suivant In direction de la route 15.Borné au nord par la propriété de Camille Tremblay, ii l'est par la propriété de Camille Tremblay, au sud par la route no 15 ct à l'ouest par un terrain appartenant à Domtar Newsprint Co.Ltd.Ce terrain faisant partie du lot numéro quarante-neuf (Ptie 49) quatrième rang au cadastre officiel du canton Iberville.Avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu au bureau du régistrateur de la première division d'enregistrement du comté de Saguenay, nu Palais de Justice de Baie Comeau, MARDI, le VINGT-HUITIÈME jour du mois d'AVRIL 1970, ù DIX heures dc l'avant-midi.Lc shérif adjoint, Bureau du Shérif, Marcel Rodrigue.Baie Comeau, le 28 mars 1970.33875-0 QUÉBEC Fieri Facia* dc Terris Québec, ù savoir: ( \"DANQUE DE MONT-(,'our Supérieure, ) REAL, corps politique No.3298 J et incorporé, ayant un bureau \\ d'affaires ù 1049, Cartier, Québec, vs GEORGES LECLERC, domicilié ù 386, rue Lafayette, Québec.« Un immeuble situé ù 385-389 Lafayette; Québec 8, et décrit comme suit: Cadastre 2301, subdivision 70 du cadastre St-Sauveur, borné au nord-ouest par le lot 2301-71, au sud-est par le lot 2301-69, au nord-est par le lot 2301-138 et au sud-ouest pur lc lot 2301-189, rue St-Rapliacl, mesurant 35' de front sur 83' de profondeur, contenant en superficie 2905', mesures anglaises, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.».Pour être vendu ù la Salle d'Assemblée, Chambre A-24, au Palais de Justice, ù Québec, le VINGT-NEUVIÈME jour du mois d'AVRIL 1970, ù DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 24 avril 1970.33882-o Fieri Facias de Terris Québec, ù savoir: ( T A SOCIÉTÉ CENTRA-Cour Supérieure, ) *-< LE D ' H Y P O T HÈ -No 805.î QUES ET DE LOGEMENT, ' corporation légalement constituée, ayant son siège social, en la ville d'Ottawa, province d'Ontario et un bureau d'affaires dans la cité de Ste-Foy, district de Québec, es CLÉMENT MARCOTTE, domicilié au numéro 445, me Jean, Duberger, district de Québec, ct RAYMOND GAGNÉ, en sa qualité de régistrateur de lu division d'enregistrement de Québec, mis en cause.De Terril Canada \u2014 Province ol Québec District of Hauterive Superior Court, / f\\CTAVE TREMBLAY, No.5932.\"\\ ' carpenter, domiciled ' and residing at Saint-Paul du Nord, district of Hauterive, plaintiff, versus VICTOR TREMBLAY, carpenter, domiciled nnd residing at Saint-Paul du Nord, district of Hauterive, defendant.A lot of land situated at Sault-au-Mouton, measuring sixty feet (60') in depth with a width of one hundred feet (100'), measured according to the direction of Route 15.Bounded on the north by the property of Camille Tremblay, on the east by the property of < 'amiIle Tremblay, on the south by Route No 15 and on the west by a piece of land belonging to Domtar Newsprint Co.Ltd.The said piece of land is part of lot number forty-nine (P.49), fourth range on the official cadastre of thc township of Iberville.With all the buildings thereon erctcd, circumstances and dependencies.To be sold at the office of the registrar for thc first registration division of the county of Saguenay, at the Baie Comeau Court House, TUESDAY, the TWENTY-EIGHTH day of the month of APRIL.1970 at TEN o'clock in thc forenoon.Marcel Rodrigue, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Baic Comeau, March 28, 1970.33875 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit: I \"DANK OF MONTREAL, Superior Court, ) body politic and corpora-No.3298.) te, having a place of business { at 1049 Cartier, Québec, se GEORGES LECLERC, domiciled at 385 Lafayette St., Québec.\"An immovable situated at 385-389 Lafayette, Québec 8, and described as follows: Cadastre 2301, subdivision 70 of the cadastre of St-Sauveur, bounded on the northwest by lot 2301-71, on the southeast by lot 2301-69, on the northeast by lot 2301-138, and on the southwest by lot 2301-189, St-Raphaël St., measuring 35\" in front by 83 in depth, having an area of 2905', English measure, with the buildings constructed thereon, circumstances nnd dependencies.\".To be sold in the Assembly Hall, Room A-24, in the Court House ut Québec, on the TWENTY-NINTH day of the month of APRIL, 1970, at TEN o'clock in thc forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, April 24, 1970.33882 Fieri Facias de Terris Québec, to wit : ( THE CENTRAL MORT-Supcrior Court, ) 1 GAGE AND HOUS-No.805.) ING CORPORATION, a \\ corporation legally incorporated, having its head office in the city of Ottawa, Province of Ontario and a place of business in the city of St.Foy, district of Québec, vs CLÉMENT MARCOTTE, domiciled at 445 Jean Street, Duberger, district of Québec, and RAYMOND GAGNE, in his capacity as registrar of thc registration division of Québec, mis cn cause 2062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n\" 13 « Un emplacement connu ct désigné comme étant la redivision numéro vingt et un de la subdivision numéro vingt et un du lot originaire numéro deux mille trois cent quatre-vingt-neuf (2389-21-21) du cadastre officiel de la paroisse dc St-Sauveur, ville de Duberger.Avec bâtisses dessus construite, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement dc Québec, 2, avenue Chauveau, Québec, le VINGT-NEUVIÈME jour du mois d'AVRIL 1970, ù DIX heures de l'avant-midi.IjC shérif adjoint, Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 24 avril 1970.33883-0 ROBERVAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Quél>ec District de Roberval Cour Supérieure,) OARAGE PERRON INC., No.33,926.\\ corporation ayant son ' siège social à Dolbeau, demanderesse r* DAME EUGÉNIA BOUCHARD, domiciliée à village Familex, Dolbeau, épouse de feu Lauréat Lavoic, défenderesse.« Lc lot dc terre connu et désigné sous le numéro quarante et un (lot 41) du seizième rang (XVI) aux plun et livre de renvoi officiels du cadastre du canton Parent, division d'enregistrement Lac St-.Iean-Oucst, avec bâtisses dessus construites, appartenances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement dc la division d'enregistrement de Lac St-Jean-Oucst, à Roberval, le VINGT-NEUVIÈME jour d'AVRIL 1970, à ONZE heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, LÉon-Mauiiice La voie.Roberval, le 19 mars.1970.33872-o \"An emplacement known and designated as being redivision number twenty-one of subdivision number twenty-one of original lot number two thousand three hundred and eighty-nine (2389-21-21) of the official cadastre of thc parish of St-Sauvcur, town of Duberger.With buildings constructed thereon, circumstances and dependencies.\" To be sold at the Québec registry office, 3 Chauvcau Avenue, Québec, on the TWENTY-NINTH day of the month of APRIL, 1970, at TEN o'clock in the morning.Raymond Hains, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, April 24, 1970.33883 ROBERVAL Fieri Facias De Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Roberval Superior Court: i OARAGE PERRON INC., No.33,926.\\ V* a corporation having ' its head office at Dolbeau, plaintiff, vs MRS.EUGENIA BOUCHARD, domiciled at the village of Familcx.Dolbeau, wife of the late Lauréat Lavoic, defendant.\"Thc lot of land known and designnled under number forty-oue (lot 41) of thc .sixteenth range (XVI) on the officinl plnn nnd book of reference of the cadastre of thc township of Parent, registration division of Lake St.John West, with buildings constructed thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the registry office of the registration division of Lake St.John West, at Roberval, on the TWENTY-NINTH day of APRIL.1970, at ELEVEN o'clock in thc morning.Leon-Mauhice La voie.Sheriff's Office, Sheriff.Roberval, March 19, 1970.33872 INDEX No I.I ARRÊTÉS en Conseil ORDERS in Council 462 \u2014 Régie des loteries ct courses en matière de systèmes de loteries ct les modalités selon lesquelles des licences peuvent être délivrées (Pouvoirs de la régie).1996 462 \u2014 Régie des loteries et courses respecting lotery schemes and the conditions upon which licenses may be issued (Powers of the board).1996 992 \u2014 Soustraction au jalonnement dc claims miniers sur certains terrains situés dans le comté de Laviolettc.2000 992 \u2014 Withdrawal from staking of mining claims on certain lands situated in the county ofLaviolette.2000 1231\u2014Camionnage, Montréal.2002 1231 \u2014 Cartage, Montreal.2002 1232 \u2014 Alimentation, Chicoutimi.2002 1232 \u2014 Food, Chicoutimi.2002 1233 \u2014 Fer & bronze d'ornementation, Montréal.2003 1233 \u2014 Ornemental Iron & Bronze, Montreal.2003 1234 \u2014 Automobile, Montréal et district.2003 1234 \u2014 Automobile, Montreal and District.2003 1235 \u2014 Alimentation, Jonquière.2003 1235 \u2014 Food, Jonquière.2003 1236 \u2014 Alimentation, détail, Chicoutimi.20W 1236 \u2014 Food, Retail, Chicoutimi.2004 AVIS divers MISCELLANEOUS Notices Chevaliers de Colomb de Hérouxville inc.Conseil Hérouxville No 6053.1987 Estate of Georges Allard (Benefit of Inventory).'.19S6 Estate of Thérèse Belleau (Benefit of Inventory).1987 Knights of Columbus of Hérouxville Inc., Council Hérouxville No.6053.1987 Succession Georges Allard (Bénéfice d'inventaire).'986 Succession Thérèse Belleau (Bénéfice d'inventaire).W QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 28, 1970, Vol.102, No.13 2063 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Demandes: Applications: Cohen, Jack.1987 Dion dit Soulière, Joseph Ernest.1989 Halmagyi, Szaholcs.1989 llristou, Hristos.1988 Mariahcgyi, Leslie.1989 Parla, James Arthur.1989 Putin, Roger.1989 Reimcr, Martina.1990 Tcitelbaum, Barry Howard.1988 Tcitelbaum, Bert.1988 Tcitelbaum, Michael.1988 Vartazarmian, Vahan Hatcher.1988 CHANGEMENT DE NOM \u2014Loi du Accordés: Chadler, Ernest Wilfrid.Uallcr, David.Lazzarone, Giuseppe.Tincro, Arnold Aaron.CHANGE OF NAME Act Granted: 1990 1990 1990 1990 CAISSES SAVINGS d'épargne et dc crédit arid Credit Unions Caisse populaire Dcsjardins dc terre des hommes (La) (Nom-Name ch.).1987 COMPAGNIES Avis relatifs ù la loi des Autorisée il faire des affaires Tingue, Brown & Co.I hart e- \u2014 demandes d'abandon dc COMPANIES Notices relative to the Act of Licensed to do Business .1990 Charters \u2014 Application for Surrender of .1977 Abitibi Meat Packers Ltd.Brooks (James E.) Cotton Company Ltd.1977 Chuck's Snack Bar Inc.1977 Coat Front Contractors Ltd.1978 District Insurance Agencies Limited.1978 Dominion Textile Investments Limited.1978 Lampron & Sons Ltd.1977 Maurice Ladies Wear Inc.1978 l'ointe Claire Shopping Centre Inc.1979 Portefeuille Landry ltée.1978 Rivet (Laurent) Cic limitée.1979 St.Martin Shopping Centre Limited., 1979 Salaison d'Abitibi limitée.1977 Victoria Clothing Limited.1979 Dissoutes Dissolved Bramley Apparel Ltd.1930 Bruce Investment Ltd.1931 Builtwell Construction Corp.1931 Curlier Industries Limited.1931 Circle Cross Corp.1931 < Construction Jodoin ltée.1931 Constructions Racine ltée (Les).1931 Couga Construction, ltée.1932 Daily Forwarders (Québec) Ltd.1932 Delta Furniture Inc.1932 Dora's Restaurant Inc.1932 Editions Kebec inc.(Les).1932 Entreprises Phibes inc.(Les).1932 Entreprises Mascouche inc.(Les).1932 Franconia Realties Inc.1933 Industries Cartier limitée.1931 Meubles Delta inc.1932 Nightwear Incorporated.1933 Perry, Grant & Associates Inc.1933 Thibodeau (Georges) inc.1933 Trans-Vision (Lakeshore) Limited.1933 United Custom Construction Ltd.1933 V.B.C.International Import Inc.1934 Divers Miscellaneous A.G.A.Construction Inc.(Nom-Name ch.).1979 Association des représentants professionnels du meuble du Québec il.') (Bègl.).1980 Au coin des petits inc.(Dir.).1980 Béliveau (Jean) inc.(Dir.).1980 Calcaires Salalierry inc.(Les) (Dir.).1980 Canadian Corporations, Limited (Dir.).1980 Centre Cardinal Villeneuve inc (Bégl- By-laws).1982 Centre d'essai «les auteurs dramatiques (Montréal) inc.(Bègl.-By-laws).1980 Children's Corner (Dir.).1980 Club d'Age d'Or d'Asbestos inc.(Bègl.- By'-laws).1981 Club Sportif Adelme (Bègl.-By-laws).1980 (.'omet Domaine Petroleum Inc.(A'oni- Namech.).1981 Compagnie dc fiducie prêt et revenu (Dir.).1981 Dc Lair Food Ltd.(Dir.).1981 Entreprises Verdi inc.(Les) (Dir.).1981 500 Selection Services Canada Limited (The) (Nom-Name ch.).1981 Informée inc.(Dir.).1981 Jeune Chambre Val d'Or inc.(Nom-Name ch.).1982 Maceachcrn (Gordon A.) (Québec) Ltd.(Dir.).1982 Nesbitt, Thomson and Company, Limited (Dir.).1982 Nesbitt, Thomson ct Compagnie, limitée (Dir.).1982 Plnnned Investments Corporation (Dir.) 1982 Programme d'investissements capitalisés, ltée (Dir.).1982 Québec Professional Furniture Representative Association (By-laws).19S0 Reconstruction G.D.inc.(Bègl.-By-laws).1982 Rigas Pernios Thessaliotian Society of Montreal (Bègl.-By-laws).1983 Savard (J.-C.) inc.(Nom-Name ch.).1983 2004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1970, 102' année, n° 13 Divers Miscellaneous (suite) (continued) Savings and Investment Trust Company (Dir.).1981 Service social Regional «le Chateauguay (Règl.-By-laws).1982 lettres palcnlcs Letters Patent A.A.Enterprises Inc.1912 Adanac électrique inc.1912 Agences André Savard inc.(Les).1913 Association Athlétique des Employés dc Division outaouaise (en Pontiac) dc Consolidated Bathurst.1913 Association de réadaptation du Québec.1913 Association des loisirs de Garthby ct Beaulac inc.(U).1914 Association Provinciale des photographes semi-professionnels et amateurs inc.1914 Beaupré, Boucher & associés inc.1915 Chanric inc.1915 Charny Sports Inc.1923 Club l'Hirondelle du Nord inc.1915 Club Optimiste dc Pointc-Gatincau.1916 Constructions Danière inc.(Les).1916 Éditions l'Abeille et l'Érable inc.(Les).1916 Entreprises A.A.inc.(Les).1912 Gagnon Propane Inc.1917 Groupe Triangle limitée.1917 Immeubles Rioux (Rimouski) inc.(Les) 1917 Journal, Le Nord de Montréal inc.1918 Livraison Lepage ltée.1918 Marsolais & frères inc.1918 Martel (Michel) inc.1919 Mcurv (Laurent) inc.1919 Micro-Art inc.1919 Monuments BM inc.1920 Motel Anse au Sable inr.1920 Multi-Net Services Ltd.1920 Multi-Net sen-ices ltée.1920 Nadon & Tremblay inc.1921 Placements Clamygo inc.1921 Place St-Aimé inc.1921 Productions musicales AC du Québec inc.(Les).1922 Quebec Rehabilitation Association.1913 Racine (J.Roland) inc.1922 Restaurant Pince Royale (St-Hyacin- the) inc.1922 Société Bclcm inc.1923 Sports Charny inc.1923 Tournoi International dc Hockey Midget dc Drummondville inc.1923 Voyageur (1969) Inc.1924 Vrac-Mar inc.1924 l
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.