Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 29 (no 4)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1972-01-29, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" c A11E8 fJ.2 r A n;7i em* QUEBEC Suiette officielle du Quebec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE Partie I: avis juridiques Part I: Juridical notices Partie II: lois et règlements Part II: Laws and Regulations (Voir sommaire en dernière page) (Refer to the last page for summary) Québec, samedi 29 janvier 1972 Règlements 1° Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3e Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des dfoiislUïA'fiditçHtçfficiel du Québec, qui rembourse, Jfljfcwsj s'iry a^M^s^oute somme versée en plus.REÇU LE Québec, Saturday, January 29, 1972 Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both officia i languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.1 FbV itII ._ou Qutat^ .Éditeur officiel du Québec, ROCH LEFEBVRE, Québec Officiai Publùher 672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i' année, n° i 5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7* La Gazelle officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Editeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Tonte demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $4 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement: du 1er janvier au 31 décembre $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; la deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre < o > signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Rocn Lefebvre.Hotel du Gouvernement, Québec, 30 avril 1969 43892 \u2014 l-52-o 5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gazette is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, The Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $4 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods: From January 1st to December 31st, $20; April 1st to December 31st, $15 and July 1st to December 31st, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertion.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Roch Lefebvre, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, April 30, 1969 43892 \u2014 l-52-o Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n\" 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.k 673 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Ventes pour taxes Sales for taxes Municipalité du comté de Vaudreuil Avis public est par les présentes donné par F.Ed.Belli veau, secrétaire-trésorier, que les immeubles ci-après mentionnés seront vendus par ancan public, dans la salle des sessions dudit conseil, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS prochain 1972, à DIX heures de l'avant-midi, pour taxes municipales, scolaires et d'église dues aux municipalités ci-après mentionnées, à moins qu'elles ne soient payées avec les (rais avant la vente.Municipality of the County of Vaudreuil Public notice is Ifereby given by F.Ed.Belliveau, secretary-treasurer, that the immoveable properties hereinafter described shall be sold by public auction in the sitting hall of the said Council on THURSDAY, the NINTH day of MARCH 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for the municipal, school and church taxes due to the hereinafter mentioned municipalities unless the same be paid with the costs before the sale.Corporation de la Terrasse Vaudreuil \u2014 Corporation of the Terrasse Vaudreuil Propriétaires Owners Nos officiels Official Nos.Cadastre Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Église Church Total Polymos Ini-.Polymos Inc.Polymos Inc.Polymos Inc Bernier.Jean-P.lul.Bourbonnais.J.-Marcel Brière.Real.Clermont.Gerald.Gilbert.Hervé.Lefebvre, Richard.Parent.Albin.Quesnel.Gilles .Skalak, François.Grenier, Ernest 182-502.180-48 182-503.180-49 .182-504.180-50.180-51, 182-505.182-180.182-24.182-32.182-158 .183-10.182-177.182-519.182-101.182-P.115 & 116 182-P.423.He Perrot He Perrot He Perrot lie Perrot He Perrot He Perrot He Perrot He Perrot He Perrot He Perrot He Perrot He Perrot lie Perrot He Perrot SI,055.64 62.95 62.94 62 95 179 40 71.25 48 95 281.26 21.85 21.85 21.85 $ 16.38 27.09 22.05 17.01 20.79 32.44 21.42 31.18 16.06 S 1,336.90 84.80 84.79 84.80 16.38 27.09 22 05 17.01 200.19 103.69 21.42 31.18 16.06 49 95 Corporation de la paroisse de Ste-Marthe \u2014 Corporation of the parish of St.Marthe Mammoii.Antonio.Desrochers, Bruno.Lavallée, Jean-Marc .\t89.90.194.moitié est lot 195 403.P.415.\tParoisse Ste-Marthe.P.Ste-Marthe.P.Ste-Marthe.\tS 62.43 23 54 63\tt 313.34 363.12 6.37\tS 67.78\tS 443.55 386.66 6.90 Corporation de Ste-Justice de Newton \u2014 Corporation of St.Justine de Newton\t\t\t\t\t\t Carrière.Adrien.\tP.174.\tP.Ste-Justine.\t$ 45.39\t$ 145.30\tDivers Mise.$186.03\t$ 378.72 Corporation de la paroisse de Très St-Rédempteur \u2014 Corporation of the parish of Très St-Rédempteur\t\t\t\t\t\t Ferland Courtemanche.Jacqueline Mongeau, Azellus.LavaUée, J.-M.et.Lefebvre, Gaston Lavallée, J.-M.Prevereau, Pierre.Renaud.J.-Hector.\tP.77.P.67, P.68.P.67.P.68.P.76.P.67.P.76.\tP.St-Rédempteur.P.St-Rédempteur.P.St-Rédempteur.P.St-Rédempteur.P.St-Rédempteur.P.St-Rédempteur.P.St-Rédempteur.\t$ 65.77 3.88 35.32 3.22\t$ 111.14 18.76 161.93 39.32 582.26 50.57 24.97\t\tS 1 76.19 22.64 197.25 39.32 582.26 53.79 24.97 674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10L' année, n° i Corporation de Vaudreuil sur le Lac \u2014 Corporation of Vaudreuil sur le Lac Propriétaires Owners\tNos officiels Officiai Nos.\tCadastre\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tÉglise Church\tTotal Club Nautique Deux____ Montagnes Inc.Belle-Plage Development Incorporated.Team Investment.Corporation\tP.1782, P.1784 P.1781, P.1782.\tSt-Michel de Vaud.St-Michel de Vaud.St-Michel de Vaud.\t\t$6,064.10 2,252.93 1,869.20\t\t$ 6,064.10 2,252.93 1,869.20 Corporation de la paroisse de St-Lazare \u2014 Corporation of the parish of St.Lazare Bierbrier, Mrs.H.Chevrier, Joseph.Geertsen, Georges.,.Mergl, Succ.Frank.Paiement.L.R.Parr, Miss A.Marguerite Pilon, Éric.Veilleux, Victorin.Largo Construction Inc.La Société d'Aqueduc de St-Lazare La Société d'Aqueduc de St-Lazare Vel-Con of America.P.188.P.14.P.518.P.167.P.568.P.168.360 P.2-361-24 P.360 P.2-361 P.24 P.25-P.29.P.482 \u2014.483.P.479.P.166.Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare.Par.St-Lazare Par.St-Lazare 2\t77\t$\t104.69 22\t89\t\t350.30 \t\t\t47.14 \t\t\t227.63 6\t71\t\t5S.51 \t\t\t80.13 17\t63\t\t328.23 \t\t\t42.76 11\t44\t\t931.82 \t\t\t3.24 37\t16\t\t708.04 6\t21\t\t100.72 Corporation de Pointe-Fortune \u2014 Corporation of Pointe-Fortune Campeau, Dame.Germaine Constantakis, Georges.Katinakis Triandafillos.Steckler, Henry.St-Jean, Mme Rosario.Houston Garth et al.P.83.:.P.18A.P.18A, ISA-18, 19, 20,.31 à 36, 40,41 P.18A.P.18A.Pointe-Fortune Pointe-Fortune Pointe-Fortune Pointe-Fortune PointenF ortune 28.38\tS 146.53 2.00\t48.54 85.00\t959.70 22.13\t118.56 \t108.48 Corporation de la paroisse de Rigaud \u2014 Corporation of the parish of Rigaud Aubin, Dame Denise.Bassot, Jean-Noël.Beaven, Marc.Bédard, Dame Leda.Bédard, Dame Leda.Béland.Claude M.Boissonneault, Mme F.Chevrier, Guy & Antonio Pelletier Chevrier, Guy & Antonio Pelletier Cappelo, Mario-Rodrigue Charlebois, J.-Pierre.Blanchette, J.-P.Courtemanche, Jean-.*.Louis et al De Laurentis, Arimondo.Derrick, Donald.Deschesnes, Claude.Dubois, Gilles.Dubois, Gilles.Dufour, Ernest.Johnson.Gérard.P.542.P.152.P.190.517-5.P.517.P.526.36-63.P.30.36-20.21, 22, 26, 27.28, 31 à 44, 47 à 55, 58, 66 à 69.36-246 à 259, 362, 363, P.366, 461 P.507.P.6.P.517.P.141.546-40.36-P.366.P.517.P.562.P.563.36-469.517-32.Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud 49.95 68.55 143.35 199.65 8.25 5.70 27.95 9.10 i 191.79 30.66 22.18 106.97 31.78 305.54 77.44 663.73 1.018.10 68.38 32.78 188.39 22.1S 10.37 81.74 88.01 32.78 285.95 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.i 675 Corporation de la paroisse de Rigaud (tuile) \u2014 Corporation of the parish of Rigaud (continued) Propriétaires Owners Nos officiels Official Nob.Cadastre Taxes munie.Munie, taxes Taxes 8C0l.School taxes Église Church fortier, Jean.Froment, Pierre.Froment, Mme Yvette .Remue, Roger.Faubert, Marcel.Faubert, Marcel.Gauthier, Hororius.Gaulin, Robert.Giraldeau, Willis.Giroux, Normand.Giroux, Normand.Gourdes, Bertrand.Hamehn, Dame Prance.Hayes.Jean.Henderson, Dame.Gilbcrte Henderson, Dame.Gilberte Joly, J.-Guy.Lulonde, J.-Paul.Larose, J.-Guy.Lauzon, Lorenzo.Lavoie, Raymond.Leclaire, Dame.Eugénie Létourneau, J.-A.Proulx, René.Mallette, Bernard.Martel, Théodule.Provost, Louis.Massia, Damasse.Oueliette, Amédé.Quesnel, Yvon.Rebts, Gaston.Rioux, Colette.Berlinguctte.Gérard Ritchie, William.Russ, John R.St-Jean, Léo.Séguin, Marcel.Sévigny, Réal.Bond, Benoit.Tinsley, Richard et al.Trépanier.Aurèle.Trépanier.Mme Aurèle.Venor.Robert 4 Cohen Joseph Venor, Robert & Cohen Joseph Jolly Realty Co.Inc.et al Jolly Realty Co.Inc- et al Rozon, Bruno Suce.P.1, 1-14, 15, 16, 19.P.529.P.525.546-48.546-32.540-31.P.36-75.P.108.P.169.36-433.36-432.P.580.36-61,36-62.P.227.P.21.P.526.P.183.P.517.P.580.P.169.P.2.36-480.P.36-75.P.29.P.103.P.142.2-14.P.30.513-16.36-P.485.P.169.P.190.P.146.P.97.P.580.P.548.517-30.546-78.P.219, P.158.66-P.30.66-31.P.4.110.P.105.178.179.P.120.Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Pur.Riguud Par.Rigaud Pur.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Riguud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud Par.Rigaud S 3.40 43.75 36.40 10.20 81.04 39.60 12.15 3.40 45.50 73.75 117.49 12.25 12.70 14.16 60.45 51.62 40.10 474.62 411.74 105.23 21.18 43.98 43.98 265.97 181.25 21.18 223.59 43.40 293.07 32.78 158.95 43.40 51.81 32.79 465.52 66.99 159.96 424.44 396.79 32.78 48.48 299.98 257.26 375.04 66.99 43.40 106.97 66.99 322.86 164.21 85.80 112.98 88.18 197.94 108.85 128.50 62.63 308.97 307.98 199.49 Corporation de N.-D.de l'Ile Perrot \u2014 Corporation of N.-D.de l'Ile Perrot Carrière.Jean-Claude.Rheted Investments Ltd The Wister Corporation.Dame Rose Wisenthal Weiner Elru Investments Ltd.Rookies.H.etoi.Olshansky, Issie et ai- D'Ambrooio, Vol.61-19-1.P.107.83, 86.87 P.102, P.105.P.106,.P.108 P.102, P.105, P.106.P.108 P.107.He Perrot.He Perrot.Ile Perrot lie Perrot He Perrot 211.49 156.00 310.66 115.37 21.74 $ 113.45 170.27 410.02 676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10k' année, n\" i Corporation de N.-D.de l'Ile Perrot (tuile) \u2014 Corporation of N.-D.de l'Ile Perrot (continued) Propriétaires Owners Nos officiels Officiai Nos.Cadastre Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Église Church Total Bavin Investments Ltd Window Holdings Ltd.Forward Holdings Ltd.Lalonde, RolanoT.Berkeley Holdings Ltd.Amini, Samuel.The Directors', the____ Veterans' Land Act Druker, Samuel.Arant, Reynold.Houle, Mme Lucie- Gravel, Henri.Barrette A.Succ.Martin, Michel.Marchand, John.Perron, Gérard.P.253.P.254, P.313 P.255, P.313 P.258.P.282.P.294.P.281, P.280.P.276.268-117, 118.268-105.268-94.288-41.P.267.266-11.266-52.P.265, 265-16 He Perrot He Perrot He Perrot He Perrot He Perrot lie Perrot He Perrot He Perrot lie Perrot He Perrot He Perrot He Perrot He Perrot He Perrot He Perrot 697.21 519.58 746.10 26.33 523.57 513.48 95.97 80.00 136.94 113.10 3.27 123.23 145.81 58.41 65.89 $4,469.42 199.67 2,133.49 7,643.20 84.55 99.84 121.00 638.99 6,066.63 719.25 2,879.59 26.33 523.57 8,056.68 95.97 164.55 136.94 212.94 3.27 123.23 266.81 58.41 704.88 Donné à Vaudreuil, ce 6e jour de janvier 1972.Copie conforme.Le secrétaire-trésorier, 44005-2-2-o F.Ed.Belliveac.Municipalité du comté de Soulanges Avis public est, par les présentes donné que les terrains ci-après mentionnés seront vendus selon les dispositions du Code Municipal, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi pour taxes scolaires, municipales et autres redevances dues aux municipalités ci-après mentionnées, à moins qu'elles ne soient payées avec les frais avant la vente, à savoir: Given at Vaudreuil, this 6th day of January 1972.True Copy.F.Ed.Belliveatj, 44005-2-2-o Secretary-Treasurer.Municipality of the County of Soulanges Public notice is hereby given that the lands hereinafter mentioned will be sold according to the provisions of the Municipal Code, on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for school and Municipal taxes, and others debts due to the municipalities mentioned below unless they are paid with the costs, before the sale, to wit: La commission scolaire de Soulanges \u2014 School Commission of Soulanges Noms\tNuméro du cadastre\tTaxes scolaires\tTaxes munie.\tRépart.d'Eglise\tTotal Names\tCadastral number\tSchool taxes\tMunie, taxes\tChurch repart.\t SainUTélesphore\t\t\t\t\t Mrs.Nelson Davis.\tP-325.\t$ 79.21\t$ 13.76\t\tS 92.96 Saint-Polycarpe\t\t\t\t\t \t.P-475-6.\tS 194.20\t$ 14.17\t\tS 208.37 Ste-Claire d'Assise \u2014 Rivière Beaudette\t\t\t\t\t Jean-Marie Delangis.793-46.$ 118.66 $ 118 66 Réal Ferland.493-74.221.65 221 66 Ronald Samuel Juver.P-884.33.81 33 81 J.Boyd & H.McDonald.P-881.199.92 199 92 Léonard Pilon.793-29.166.02 166 02 Xiste Ravary.P-887.33.82 33 82 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.i 677 Village de Saint-Zotique Noms Names Numéro du cadastre Cadastral number Taxes scolaires School taxes Taxes munie.Munie, taxes Répart.d'Eglise Church repart.Total Hector Daoust.Steven Demers.Guy Lamontagne.Maurice Lemieux.Sébastino Marganti.Marie J.D.Perron.Dame Yvette Pinsonneault.Raphaël Stromei.Roland Villeneuve.Arthur & Rolland Villeneuve.P-682.$ 107.11 769-5.31.78 769-96.61.24 769-43-44 .241.97 P-767.42.56 767-4.213.40 10-62.251.53 26-184.17.48 P-773 .94.74 P-773.69.22 2.80 5.81 30.40 262.09 4.43 23.22 S 11.05 2.03 12.73 107.11 34.58 61.24 253.02 50.40 243.80 526.35 21.91 117.96 69.22 Village de la Station du Coteau Jean-Guy Deguire.P-166.Mme N.W.Jourdenais.P-143.S 245.04 133.76 159.08 50.45 404.12 184.21 Paroisse de Saint-Ignace du Coteau du Lac \u2014 Parish of Saint-Ignace du Coteau du Lac Fondation pour la Culture et l'Éducation.P-10-P-ll.«4,087.11 «4,087.11 Corporation municipale de la paroisse de Sainte-Claire d'Assise Municipal corporation of the parish of Sainte-Claire d'Assise Fernand Dubé.P-889.Dame James Dawson.P-885.H.J.O'Connell.861-862.H.J.O'Connell.881-882.Jean-Paul Touchette.P-884.S 259.95 160.03 560.98 441.35 42.28 28.80 21.59 87.88 89.47 302.23 28.80 181.62 648.86 530.82 La Fabrique de la paroisse de Saint-Zotique \u2014 The Fabric of the parish of Saint-Zotique Gilles CouUlard.Alain L'Heureux.Dame Jacques Hébert née Monique Sauvé.René Loiselle et Dame Irène Lefeb- vre.Dame Georges Picinbono, née E.Caudine Brevin.Denis St-Pierre.Ken Hall.Rock Trépanier.Dame Huguette Isabelle Cadieux.Adrien Pothier.André Marteau.Jacques Hébert.Armand Latour.EmUio St-Michel.Dame Rita Amyot, L.Z.Vincent .J.Denis Leduc.Albert Laitre.Dame Estelle StrDenis.10-5.P-19.57-19-20-21-22-23-24, 57-P-18, 57-P-25.660.683-1.P-684.P-744.767-6.767-12-44-45.776-96.767-109.768-P-16, 768-17-35.768-80, 768-100.770-3.P-776.695-14.767-198, 768-139.P-773.220.20 75.64 S 211.28 88.83 S 23.76 33.74 455.24 198.21 340.48\t656.27\t148.11\t1,144.86 571.68\t1,457.83\t64.25\t2,093.76 1,092.29\t1,275.52\t132.92\t2,500.73 \t21.42\t10.18\t31.60 21.65\t6.65\t6.70\t35.00 139.60\t37.38\t15.86\t192.84 519.12\t118.62\t52.53\t690.27 292.25\t77.67\t50.39\t420.31 \t10.05\t4.69\t14.74 85.42\t\t38.62\t124.04 83.52\t\t24.81\t108.33 104.50\t74.36\t15.23\t194.08 41.58\t6.64\t6.70\t54.92 39.12\t3.40\t5.20\t47.72 39.12\t5.83\t5.20\t50.15 77.35\t7.56\t7.42\t92.33 678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101- année, n° l La municipalité de la paroisse de Saint-Ignace de Coteau du Lac The municipality of the parish of Saint-Ignace de Coteau du Lac Noms Names Numéro du cadastre Cadastral number Taxes scolaires School taxes Taxes munie.Munie, taxes Répart.d'Eglise Church repart.Total Almansor Audette.P.375.René Besner & René Levae.P-234.Germain Carignan.P-16.Léonide Chiasson.149-9.Venise Motel Inc.157-1,233-1.Dame Marguerite Sinray.P-15.P-16, P-21, P-24.Jean Valiquette.122-75-76.Martial Ménard.122-191-192.Léon Ménard.P-409, 122-186-187.122-188-189.S 194.23 39.19 87.30 134.39 2,119.73 17.71 384.78 20.60 20.98 20.89 24.21 139.93 2.13 3.14 3.14 25.60 $ 171.69 49.3S 3.33 29.63 I 214.73 60.17 108.19 158.60 2,259.66 2.13 3.14 20.85 410.28 \tLa corporation municipale du Village de Coteau du Lac\t \tThe municipal corporation of Village de Coteau du Lac\t \t.120-28.120-29-30.S 447.97 S 272.25\t$ 720.22 La commission scolaire de Vaudreuil \u2014 The school commission of Vaudreuil\t\t Michel Asselin.P-344.S 585.74 Michel Asselin.P-344 .507.90 Carmen Binette.P-308.918.55 Mlle Françoise Brisebois.P-128.243.98 Valentino D'Ambrosio.P-263.159.74 Valentino D'Ambrosio.83-P-84.1,218.70 Valentino D'Ambrosio.57 .474.94 Hector Daoust.116.14.88 Georges L-imbert.217.49 H-342-5.14-342-6, H-342-7, H-342-8, ^-342-9, K-342-10, U-342-10, H-342-11, H-342-12, H-342-13, J4-342-14, H-342-15.\"4-342-16.'X.-342-17.14-342-18, H-342-19, K-342-24, Î4-342-25, Î4-342-28, H-342-29, M-342-30, \"4-342-31, J4-342-32, \"4-342-33, S4-342-34.>/£-342-35, 14-342-36.14-342-37.Î4-342-38, H-342-39.K-342-40, 14-342-41, Mi-342-42, H-342-43, \"4-342-44.\"4-342-45.14-342-46, 14-342-47, 14-342-48, H-342-49, H-342-50, J4-342-51, \"-j-342-52, ^-342-53.\"4-342-54, J4-344-5, ^-344-6.¦4-344-7, 14-344-8, \"4-344-9, 14-344-10, 1/5-344-11, J4-344-12, Î4-344-13, H-344-14, U-344-17, \"4-344-21, U-344-26, \"4-344-29 H-344-30, ^-344-31, 14-344-32, 14-344-33.14-344-34, J4-344-35.14-344-37, \"4-344-38.H-344-39, H-344-40, K-344-41, VS-344-42 H-344-43.Î4-344-44, 14-344-45, J4-344-46, J4-344-47, \"4-344-48, \"4-344-49, \"4-344-50, \"4-344-51.t 767.43 607.90 918.55 293.36 159.74 1,218.70 474.94 18.21 247.12 La corporation municipale de la paroisse de Saint-Joseph-de-Soulanges The municipal corporation of the parish of Saint-Joseph-de-Soulunges Lionel Ravary.P-312.Istvan Bacsfalusi.143-P-7, 143-11, 143-P-7-5.Antonio Gangi.139-13.Vicenzo Gangi.139-4.Michel Deschamps.342-22-23.Jacques Archambault.130-5.Guy Archambault.130-IO-P-17-P-I8-P-130.Raymond Vidal.140-16.Soulanges Holding.P-274, 344, P-322, P-262.P-344, P-139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146.188.99 28.96 7.71 8.39 72.65 77.04 74.50 3,231.54 133.27 16.36 4.58 4.94 66.02 55.40 53.69 58.77 722.20 322.26 45.32 12.29 13.33 138.67 132.44 128.19 58.77 3,953.74 L'énumération abrégée des numéros cadastraux a été autorisée par la Commission municipale de Québec, le 15 décembre 1971.Donné à Coteau Landing, ce 3e jour de janvier 1972.(Sceau) Le secrêtaire-lrêsorier, 43991-2-2-0 Laurier Léger.The abreviated enumeration of the cadastral numbers has been authorized by the Québec Municipal Commission on December 15, 1971.Given at Coteau Landing, this 3rd day of January.1972.(Seal) Laurier Léger, 43991-2-2-0 Secretary-Treasurer. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 679 Municipalité du Comté de Montcalm Avis public est par les présentes donné par le Secrétaire-trésorier de la Corporation du Comté de Montcalm, que JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS, mil neuf cent soixante-douze, à DIX heures de l'avant-midi, en la salle municipale du Comté de Montcalm, à Ste-Julienne, les immeubles suivants seront vendus à l'enchère publique à défaut de paiement des taxes auxquelles ils sont affectés et des frais encourus, sujet néanmoins au paiement de ce qui pourrait être dû au Gouvernement Provincial, pour le prix desdits lots, savoir : Municipality of the County of Montcalm Public notice is hereby given by the undersigned Secretary-Treasurer of the Corporation of the County of Montcalm, that on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, nineteen hundred and seventy-two, at TEN o'clock, in the forenoon, in the municipal hall of the County of Montcalm, at Ste-Julienne, the following immoveable properties will be sold at public auction in default of payment of taxes for which they are liable, and the costs incurred, subject however to the payment of what could be due to the Provincial Government for the price of said lots, to wit: Corporation municipale du canton de Rawdon \u2014 Municipal Corporation of the Township of Rawdon Noms et prénoms Names and surnames Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre \t\tTaxes\tTaxes\tFrais et Rang\tCanton\tmunie.\tscolaires\tintérêts Range\tTownship\tMunie.\tSchool\tCosts \t\ttaxes\ttaxes\tand int.10\tRawdon____\tS 18.77\tS 14.50\t 10.\tRawdon.\t5.83\t3.27\t 8.\tRawdon____\t64.98\t310.26\t 5.\tRawdon____\t37.70\t129.43\t 10\tRawdon.\t6.01\t26.95\t 11.\tRawdon____\t7.51\t14.48\t 5.\tRawdon.\t15.58\t20.30\t 6.\tRawdon.\t27.96\t38.7,7\t 6.\tRawdon____\t34.69\t142.66\t 10.\tRawdon.\t\t15.77\t 10.\tRawdon-\t5.83\t\t 4.\tRawdon.\t12.60\t68.73\t 9.\tRawdon____\t248.51\t71.98\t 6.\tRawdon____\t14.01\t101.46\t 9.\tRawdon.\t9.61\t19.00\t 8.\tRawdon.\t29.91\t46.22\t 8\tRawdon.\t27.62\t61.52\t 4.\tRawdon.\t55.86\t4.66\t 11\tRawdon.\t16.72\t35.75\t 7.\tRawdon____\t\t27.94\t 4.o\tRawdon.\t229.60\t298.80\t o.4.\tRawdon.\t169.78\t138.73\t 7.\tRawdon.\t14.29\t20.30\t 6 -\tRawdon-\t10.46\t20.42\t 8.\tRawdon.\t12.79\t41.47\t 8.\tRawdon-\t8.22\t24.82\t 10\tRawdon____\t5.83\t7.84\t 8.\tRawdon____\t37.01\t57.25\t 11.\tRawdon____\t6.29\t28.24\t 6.\tRawdon.\t29.09\t62.23\t 8.\tRawdon.\t\t14.56\t 11.,\tRawdon.\t1.00\t\t 7.\tRawdon____\t1.00\t\t 9.\tRawdon.\t9.86\t67.23\t 11.\tRawdon.\t8.90\t16.87\t 6.\tRawdon.\t47.65\t68.03\t 5\tRawdon.\t11.49\t24.15\t 8.\tRawdon.\t29.91\t66.68\t 5.\tRawdon.\t7.39\t36.12\t 8\tRawdon.\t8.34\t47.45\t 10\tRawdon.\t5.83\t\t 10\tRawdon.\t5.83\t7.84\t 10.\tRawdon.\t6.83\t10.41\t 10\tRawdon.\t32.86\t16.98\t 6\tRawdon.\t116.09\t267.93\t 10\tRawdon.\t60.61\t45.23\t Balfe Ryckart N.Beaulieu Y von.Brazil John.Brown Robert & Paul.Cardin Leopold.Carraoniso Cosmo.Dayback Mme Ludmilla.Desrosiers J.T.Gabriel.Desroches Hector.Diamond Lucien.Dupuis Henri.Kllson Antony.Gamrat Inc.Guerra Joseph.Jeffrey Henri.Krzisnik Ivo.Ladouceur Robert.Laurentian Hunt & Country Club Lebel.Mme Angéline.Les Developments Rawdon.Les Terres Laurentiennes.Magnan, Claude.Main ville.Hector.Mistioni, Antonio.Mrakic, Anton.Nahorniak, Nicholas.Nelson, Normand.Oatway.Robert.Penta Donato Delli.Picard, Claude.Pontbriand, Mme Henri.Inconnu.Inconnu.Inconnu.Renaud, Raymond.Robidoux, Philippe.Roza , Georges.Sachewski, Alex.Savard, Paul.Stojanovic, Mladem.Batson.Sinclair.Sitcoff, Sam.Soto.Louis.Ladouceur, François St-Onge.St-Germain.André.Sigouin, Mme Gilles.i P 7b____ 16b-258.P.9c.P.12c.P.16A.P.14b.P.14A.P.7c____ P.7c.16b-243.16b-269.P.23A.P.6A.P.7c.P.16A.P.11A.P.16b.P.20A.11-340.P.12c et P.12b.P.20b.22c.P.23A.17C-17.P.7c.P.9c.P.15.16b-214.P.7c.P.14b.8b-84.85 & 86.P.13 & P.13b.P.4c.P.22d.1 b.P.10A.6A-52 et 53.P.16A.P.5b.P.21c.P.5b.16b-279.16b-183.16b-306.16b-223.P.4A.P.28c. IjMI GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101' année, n° l Corporation municipale de St-Liguori \u2014 Municipal Corporation of St.Liguori Noms et prénoms Names and surnames\tNuméro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre\tRang Range\tCanton Township\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scolaires School taxes\tFrais et intérêts Costs and int.\tTotal \t248.\t\tSt- Liguori.St-Liguori.\tS 1.20 28.78\tt 4.39 104.79\tS 0.76\t% 6.34 141.39 Pasatino.Dame Angelo et Gusepte\tP.44.\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Corporation municipale de la paroisse de Chertsey et du canton Wexford Municipal Corporation of the Parish of Chertsey and Township Wexford Bérubé, Gaston.Bordeleau, Maurice.Côté, Mme Manon.Doré, Jean-Noël.Frascadore.Bruno.Hêtu.Roger.Labelle.Mme Jean.Lacombe, Mme Armand.Suce.B.Owens Lobley____ Roy, Gravel Régina.Roy, Paul-Emile.Toth, Dme Kalman.(Margit Toth) Williamson, Walter.Akkaoui Claude A Inc.Alarie.Guy.Ares Inc.Ares, Napoléon.Aubé.Guy 4 Uxor.Auberge Grande Vallée Inc Aucoin, Joseph.Barry, Gorden Maogan.Boisvert, Claude.Chartrand, Mlle Dora.Côté, Maurice.Coulorobe Adrien.Couture, Martial.Daigneault, Clément.Daigneault, Suzanne 4 Ares Napoléon.Denogens, Jean-Claude.DeVlieger.Patrick.Domaine Gentilly Inc.Domaine Grande Vallée Inc.Domaine Grande Vallée Inc.Domaine Grande Vallée Inc.Domaine du Lac Michel Inc.Duchesne, Leopold.Duval, Jacques Dot.Frechette, Dme Frank.Funaro, Alfred.Gauthier, Serge.Germain, Dme Rosette.Gluckman, Dme Thérèse (Bardoux)., P.41.P.48A.P.57.P.52.P.62.P.57.P.52.42 s 20.P.43.P.44.P.44.P.57.P.42 et P.47b.P.54.63.55 s 1 4 17.P.47A.30As5.25 s 10, 11, 12, 13,44 4 45.26 s 1, 5, 6.13, 18, 19, 20, 28, 29 4 30 P.10.P.37 4 37 s 221.37 s 107 4 108.P.8b.7A s 13 4 14.39 s 230.19 s 6 et 20 s 2.P.36 4 37.P.29.37 s 95 4 155.38 s 30, 81 4 248 39 s 204, 205, 206, 266 4 367.35 s 35, 41,42 4 46____ 36 s 16 et 37 s 222 et 38 ( 57 et 58.35 8 76.39 s 393.P.27.55 s 4 et 55 s 5.P.34 ouest.P.38 ouest.36 4 37 ouest.35 ouest et P.38 ouest.25 4 26.P.19 s 9.39 s 286 4 286.P.39.P.35 4 36 et 35 s 2 et 36 a 11.P.10.P.9.P.29____X.46b et 47.64 et 66.,.2.8.4.8.7.7.7.7.2.2.7.8.7.4.6.7.7.7.6.Wexford.Wexford.Wexford.Wexford.Wexford.Wexford.Wexford.Wexford.Wexford.Wexford.Wexford.Wexford.Wexford.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chestsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.8.40 11.85 14.00 22.40 114.80 119.50 18.60 128.80 28.53 80.15 8.00 7.00 16.00 1.40 34.44 12.00 449.60 4.76 7.00 0.70 14 00 170.80 92.00 59.92 23.52 4.20 82.00 8.40 28.00 116.20 20.00 16.00 3.08 8.40 15.40 5.00 34.00 14.00 J16.00 13.48 26.15 36.07 67.00 274.33 294.54 28.57 99.60 23.33 127.05 45.70 108.56 133.90 135.41 34.28 1,354.99 12.28 22.86 39.99 4.00 64.92 262.82 185.34 56.39 8.56 234.26 6.50 45.70 57.14 45.69 7.93 15.27 28.57 36.73 36.07 331.38 0.80 3.87 4.30 1.60 19.48 0.80 22.45 3.54 1.60 0.80 13.93 3.75 6.65 0.80 11.22 2.27 2.10 2.42 1.60 2.61 1.29 5.80 0.80 16.56 7.43 1.60 1.56 14.87 1.60 6.35 3.62 1.60 2.40 2.74 2.40 3.45 19.80 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10i, No.i 681 Corporation municipale de la paroisse de Chertsey et du canton Wexford (tuile) Municipal Corporation of the Parish of Chertsey and Township Wexford (continued) Noms et prénoms Names and surnames Bamelin Fernand & Rossi S.Hudon, Fernand.Investment C.C.Jardin St-Théodore.Juteau, Rosaire.Laplante, Roger & Yvon Martigny Noël & Al! Martin, Leopold.Martin, René.Martineau, Joseph G.Meilleur, Claude.Monette, Robert.Morin, Paul.Plante, Fernand.Plante, Léonce & Al.Poirier, André.Pouplier, André & Uxor.Raymond, André.Riportella, Ferdinand.Riportella, Ferdinand- Riportella.Ferdinand.Roy, Jean Claude.Skclly.Peter.Neveu Suce.Misael.Sylvestre, Benoit.Taillon, Lionel.Therrien, Normand.Trottier, Gabriel.Zabartany Vassef.Wanca.William.Terres Laurentiennes Inc Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre 39 s 271, 272, 273,274, 275, 276, 307, 308, 311, 312, 319, 320, 327, 328, 339, 340, 346, 347, 348 & 349.P.12.26 s 52 et 53.7As2.3,5,6,7,8.9, 10, 11, 12, IS, 16, 19, 20, 17, 21.22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.30,31, 32, 33.34.35, 36.37, 38,39, 40,41,42,43.P.39.37 s 66.39s295 et 296.39 s 396.35 s 77.38 s 285 et 287.P.5A.39 s 313 et 314.P.lib.35 s 65.38 s 237 et 238.P.14 et P.16.39 s 253 et 254.38 s 170.38 s 293, 295, 297 et 299 38 s 266, 267 et 268.P.19A.37 s 161 et 162.36 s 8 et 9.P.47.53.18 s 6.P.14.37 s 116 et 118.Bloc C27 s D8, 12, 16, 18, et 21, P.35.P.17-.P.28A et P.29.38 s 1 et 2, 39 s 277, 278, 279, 280, 281, 282, 287.288.289, 290.291, 292.301 ; 35 s 39 et 40.39 s 369, 370, 371.372, 381,400.4Û7.408 et 409.29A s 116 et 117, 30A s 1, 2, 3.38 s 350, 351.354.39-s 27.28, 30, 183, 337 et 338.29C s 114, 115.116.117, 118, 143, 144 et 145, 37 s 78.29Cs 1,2,3,4, 107.127 et 128; 37 s 117 et 119.28 8 88.90, 100, 101, 102, 121, 132, 133, 134 29C s 104, 105 et 106.28 s 89, 104, 105, 106, 107, 108, 109.110, 111.112.113.114,115.28 s 1,7, 118.119, 120.122, 124, 125.126, 141, 143, 144.145 et 146.29C 8 6, 0, 7.8, 11.108, Rang Range 4 7 2 7 7 7 7.s 7 6 7 1 8 7 fi 7 7 7 7 4 7 -1 3 5 8 7 4 3 S 7 8.7 5 7 6.7.5.7.6.5.6.5.Canton Township Chertsey.! 38.92 Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chortooy.Taxes munie.Munie, taxes 33.60 48.00 155 96 14.00 88 10 5.60 4.76 4.76 11.20 2.80 16.00 4.20 3.92 23.00 3.92 1.96 24.00 13.72 298.00 40.00 6.00 14.00 22.40 14.00 22.40 4.00 142.40 20.00 112.00 33.88 35.00 36.40 24.08 20.16 18.20 33.60 36.40 42.00 40.60 Taxes scolaires School taxes S 100.27 53.16 138.61 347.67 36.07 145.87 11.43 7.31 9.73 22.85 6 95 45.70 8.66 6.42 84.77 8.00 6.33 86.57 38.45 657.07 162.27 17.15 57.70 36.07 37.48 9.93 112.64 57.14 288.54 95.22 104.93 152.49 51.93 46.90 86.58 93.77 108.21 111.49 Frais et intérêts Costs and int.$ 7.47 3.20 1.60 24.71 4.00 2.40 2.52 .80 3.22 2.40 1.42 3.75 2.36 .80 6.18 2.32 .80 5.34 2.89 .80 9 55 2.06 .80 6.15 3.49 3.68 1.58 .80 4.42 21.58 .80 682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101' année, n° 4 Corporation municipale de la paroisse de Chertsey et du canton Wexford (suite) Municipal Corporation of the Parish of Chertsey and Township Wexford (continued) Noms et prénoms Names and surnames Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.29As 1,2,3,4,5,6.7,8, 38, 39,40, 41,42, 43,44,45 73.74, 75, 76.77, 78, 79, 80 110.Ill, 112, 113, 114.118, 140, 141, 142, 143, 147, 148, Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre Rang Range 5.7.5; 7.7.7.Canton Township Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.109, 110, 111, 112, 113, 123.124, 125.126.38 s 8, 39 s 1,2,29, 158, 159, 325, 326, 342, 343.38 s 11, 12, 228, 231, 320 et 321, 39 s 93, 94, 114.250,255,256 et 267.28 s 59, 61,62.63, 64, 65.66, 67, 6S, 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 103.28 s 147 et 148; 38 s 28.29, 255.356, 322 et 323; 39 s 302 et 249.35 s 56, 58, 59 et 60.P.14.P.9 et 10.'.P.35.P.36 s 101.28 s 60 et 123.29C s 103 37 s 120, 121 et 123.P.15 et P.17A;39s382.35 s 7.29 s 13.39 s 186, 187.210 et 211, 38 s 76., ' Chertsey 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21.22, 23, 24 46, 47, 48.49, 50.51, 52.53.54, 55, 56, 57, 58.59, 86.87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94.95.96, 97, 98, 99, 119, 120, 121, 122, 123, 124,125, 126.127.128,129, 149, 150, 151, 152, 163, 154 et 155.39 s 100, 101, 110, 119, 228 et 229.16 s 16, 17, 23,29, 30, 31,39,40,41.42, 43, 46, 47, 48, 52, 61 et 62.16 s 63, 66, 71,80.81, 82, 85, 86, 87, 88, 89.90, 91 et 95, 17A s 2 et 3.16 s 38 et 92.17As4, 6, 6, 7, 19, 24, 25, 26, 27.28,29,30 et 31.28 s 20, 21,22, 23.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33.34, 35 et 36.28 s 37, 38, 39, 40,41, 42.43.44, 45.46, 47, 48, 49, 50, 61, 52, 53.54.69,81,86,87,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.99, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138.25 s 78.79, 80.81,82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.92, 93, 94, 95.96.99.100, 101, 102, 103 et 104, 26 s 2, 3.4, 11, 12, 31.32, 33.29 s 2.6.12.16, 17,24, 25, 26, 35 s 1.3, 6, 11, 36 s 10.29 C s 12, 23, 24.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46.46, 47,48, 49, 60.Taxes munie.Munie, taxes 16.52 24.36 47.60 21.00 8.96 90.23 12.60 49.60 35.70 16.36 Taxes scolaires School taxes $ 45.27 72.04 127.67 96.94 13.05 479.72 124.68 75.24 40.68 Frais et intérêts Costs and int.S .80 .80 Total 61.79 96.40 175.27 117.94 22.01 91.03 492.32 174.28 111.74 67.04 ¦1,253.79 413.66 840.23 , 25, 26, 27.28.29, 30, 31, 32, 33, 34,35.36,37, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 130, 131, 132.133, 134, 135, 130, 137, 138, 139, 7.\tChertsey.\t10.08\t25.99\t\t36.07 6 .\tChertsey.\t52.64\t135.60\t\t188.24 G.\tChertsey.\t50.96\t131.28\t\t182.24 6\tChertsey.\t36.56\t91.63\t\t127.19 5.\tChertsey.\t84.00\t216.41\t\t300.41 6.\tChertsey.\t126.00\t324.62\t\t450.62 7.\tChertsey.\t63.28\t163.01\t1.60\t227.89 7.\tChertsey.\t79.52\t207.39\t\t286.91 6.\tChertsey.\t259.28\t667.96\t\t927.24 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.i 683 Corporation municipale de la paroisse de Chertsey et du canton Wexford (suite) Municipal Corporation of the Parish of Chertsey and Township Wexford (continued) Noms et prénoms\tNuméro du lot et du cadastre\tRang\tCanton\tTaxes munie.\tTaxes scolaires\tFrais et intérêts\tTotal Names and surnames\tNumber of lot and cadastre\tRange\tTownship\tMunie, taxes\tSchool taxes\tCosta and int.\t Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée .\t51.52, 53, 54, 55, 66, 57, 68, 59, 60 à 102 inclus 119, 120, 121, 122, 129 à 142 inclus.36 s 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 et 16, 17, 18, 19 et 22; 16 s 15.\\7A s 32,36,37, 38, 39, 40, 43, 44.\t8.\tChertsey.Chertsey.\tS 53.48\tS 173.89\t\t$ 227.37 \t\t5.5.\t\t57.40\t124.29\t\t181.69 Immeubles Chertsey Ltée .Immeubles Chertsey Ltée .Immeubles Chertsey Ltée .\t28 s 8.11, 12, 17, 18, 19.31 s 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 11.13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32 38 s 117, 155, 156.\t6 7.\tChertsey.Chertsey.Chertsey.\t105.00 44.80\t237.43 124.52\t\t342.43 169.32 \t39 s 41, 42, 43, 44,45, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 59, 60, 63.28sl39, 140, 142, 167.37 s 44, 52, 53, 68, 173, 219.39 s 175, 176, 242, 243, .268, 269, 341, 354.25 s 27, 28, 29, 30, 32,\t5.7\t\t18.34\t52.07\t\t70.41 Immeubles Chertsey Ltée .Immeubles Chertsey Ltée .Immeubles Chertsey Ltée .ImmeublesChertsey Ltée .\t\t7 7.\tChertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.\t15.68 72.24\t40.43 228.16\t\t56.11 300.40 \t33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 54, 57, 58, 59, 60, 61.63, 64, 65.66, 67, 6% 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.30A s 4, 6, 7, 8.9, 10, .11,12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31.32,33.29 s 8, 9, 10, 11,20, 21.25 s 14, 21, 22.\t5.\t\t58.80\t.167.21\t\t226.01 \t\t7.\t\t40.32\t28.57\t\t68.89 \t\t\t\t\t\t\t Immeubles Chertsey Ltée .\tP.30.\t6.\tChertsey.\t95.50\t319.25\t\t415.55 \tP.26.\t7.\t\t\t\t\t Immeubles Chertsey Ltée .\tP.25.\t7\tChertsey.\t29.58\t139.60\t\t169.18 \t38 s 334.335, 336, 337.73.39 s 35, 36, 37.38, 39, .40.35 s 49.36 s 2.P.30A.\t\t\t\t\t\t Immeubles Chertsey Ltée .\t\t8 5.\tChertsey.\t139.21\t603.74\t\t742.95 \tP.29 et P.39.\t7\t\t\t\t\t Immeubles 50-50 Ltée.\t39 s 180.\t7.\tChertsey.\t69.16\t178.17\t\t247.33 \t\t8.\t\t\t\t\t Immeubles 50-50 Ltée .\t38 s 37, 38, 49, 50, 157,.\t7.\tChertsey.\t22.68\t64.62\t\t87.30 Immeubles 50-50 Ltée.\t158, 163, 183, 286, 292.38 s 164, 165, 166, 167, .303,314,326, 327,328.39 s 66, 182.39 s 67, 68, 96, 107, 108, 161, 162, 164, 165, 179, 233.29 s 3, 4, 14.15.\t7 7.\tChertsey.Chertsey.Chertsey.\t44.80\t115.41\t\t160.21 Immeubles 50-50 Ltée.Immeubles 50-50 Ltée.\t\t7 7.\t\t19.88 25.28\t51.20 73.51\tS .80\t71.08 99.59 \t36 s 9.35 s 6.8, 9.\t8\t\t\t\t\t \t37 s 51, 105, 109, 111,\t7.\tChertsey.\t28.56\t75.17\t\t103.73 \t135, 189.38 s 36, 36, 283, 284, 301, 355.\t7\t\t\t\t\t \t\t7\t\t\t\t\t 684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101' année, n' A Corporation municipale de la paroisse de Chertsey et du canton Wexford (tuile) Municipal Corporation of the Parish of Chertsey and Township Wexford (continued) Noms et prénoms Names and surnames\tNuméro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre\tRang Range\tCanton Township\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scolaires School taxes\tFrais et intérêts Costs and int.\tTotal Brassard, Marie Josée.\t39 s 375, 376.378,391, .392, 394, 395, 397, 398, 399, 401, 402, 403.35 s 61, 62.63.64.66,.67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 78.79.80,81.\t7.8\tChertsey.\tS 100.52\t$ 258.87\t\tS 359.39 Corporation municipale de la paroisse de St-Jacques \u2014 Municipal Corporation of the St.Jacques Parish\t\t\t\t\t\t\t Mathieu, Georges-Etienne .\tP.692 et 699 et 737.\t\tParoisse .St-Jacques\tS 64.89\tS 357.62\tt 14.74\tS 437.25 Corporation municipale de Notre-Dame de la Merci \u2014 Municipal Corporation of Notre-Dame de la Merci\t\t\t\t\t\t\t Thibault.Armand.Tremblay, Philippe .\tP.6.,-vv P.11.39b s5.'____ 30A s 63 & 64.\t3.7.6.11.11.\tChilton____ Chilton____ Chilton.Chilton.'.Chilton____\t\tS 1962 82.68 167.01 66.43 16.00\tS 6.78 7.92 14.77 6.26 4.27\tS 26.40 90.60 181.78 71.69 20.27 Corporation municipale du \u2022 Lac Paré \u2022 \u2014 Municipal corporation of the \"Lac Paré\" Ares.Napoléon.Brisson, Lucien.Bida), Mlle Francine .Delorme, Jean-Guy .Jacques, Albert.Dupere, Philippe.Fontaine, Major.Fortin, Jean-Paul.Girard, Marcel.Jaccottey.J.L.Lacombe, Lucien.Laplante, Victor.Mascool, Alwin.Ouimet, Gérard.Proulx, Hubert.Riportella, Ferdinand.Sirois, Dame Benoit.St-Jean, Y von.Tremblay, Aline.Wiedman, Roland.Maynard.Jean.Lavoie, Armand.Renzetti, Dame El.Heins, James.Les Terres Laurentiennes Archambault, Marcel Beaudry, Jean-Pierre., Laurencelle, Rodolphe.Le bel, Réal.Punde, Peter.Sanos, Jean.Nadon, Gérard.Durand, Marguerite.Letendre, Jérôme.Miron, Arthur.Domaine Bois Franc Inc.Trembluy, Jean-Guy.24 s 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 & 118.19 s 3, 6.23 s 250.19 s 181.19 s 181.96, 97.100 et .101 24 s 490 & 503.19 s p.435 &436.21 s 14.24 s 16, 162, 163, 164____ 23 s 129, 130, 131.24 s 13, 14.19 s 699.22 s 205, 206.22 s 67.16 s 86, 87, 88.19 s 313.24 s P.361.19 s 276.24 s 519, 520.17 s 98.19 s 1,2.17 s41.24 s 77.16s 121.16 s 23.19 s 680, 681.17 s 104.24 s 203.17 s 45, 46.24 s 26.24 s 64, 76.19 s 634, 635, 636,637.24 s 392, 393.P.24.P.22.P.18.P.18, P.19, P.20, P.21.P.21.7.\tChertsey.\t\tS 382.07 8.\tChertsey\t\t 7.\tChertsey.\t\t52.69 7.\tChertsey.\t$ 6.00\t18.37 7.\tChertsey.\t\t47.44 7.\tChertsey.\t\t45.26 7.\tChertsey.\t\t206.74 8.\tChertsey.\t\t221.48 7.\tChertsey.\t\t283.43 7.\tChertsey.\t\t648.62 7.\tChertsey.\t36.31\t118.10 \tChertsey.\t13.28\t55.13 7.\tChertsey.\t\t79.60 7.\tChertsey.\t43.59\t192.88 6.\tChertsey.\t\t406.71 7.\tChertsey.\t\t12,05 7.\tChertsey.\t\t418.87 7.\tChertsey.\t\t18.37 1\tChertsey.\t\t91.65 6.\tChertsey.\t\t318.26 7.\tChertsey.\t10.18\t36.73 6.\tChertsey.\t34.76\t222.75 7.\tChertsey.\t10.18\t23.84 \tChertsey.\t72.45\t162.49 6.\tChertsey.\t\t224.43 \tChertsey.\t22.73\t188.64 6.\tChertsey.\t6.63\t 7.\tChertsey.\t9.82\t 6.\tChertsey.\t14.68\t36.89 7.\tChertsey.\t32.81\t85.81 7.\tChertsey.\t19.20\t 7.\tChertsey.\t10.48\t16.76 7____.\tChertsey.\t47.08\t70.12 7.\tChertsey.\t\t343.41 8.\tChertsey.\t\t311.64 6.\tChertsey.\t\t71.19 8.\tChertesy.\t413.86\t874.86 7.\tChertsey.\t\t102.51 S 382.07 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.k 685 Corporation municipale de Ste-Julienne \u2014 Municipal Corporation of Ste.Julienne Noms et prénoms Names and surnames Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre Paroisse Parish Taxes munie.Munie, taxes Taxes scolaires School taxes Frais et intérêts Costs and interests Cartier, Albéric.Giovani, Cianci.Desjardins, Alexandre.DiLena Frank et Giovanni & Al.Forget, Paul.Inconnu ou Richard, Odilon.Jémus, Marcel.Lac Grégoire Realties Corp.P.806.P.931.P.650.62 s 1 à 14.200.598.P.818.Ste-Julienne.Ste-Julien ne.Ste-Julienne.Ste-Julienne.Ste-Julienne.Ste-Julienne.Ste-Julienne.Ste-Julienne.S 54.25 48.40 43.40 94.95 2.80 33.85 266.46 141.13 177.42 81.58 26.55 369.82 9.78 212.08 830.39 No de lot et cadastre \u2014 Lot and cadastre No.: 873 s 4 et 874 s 6.7, 8, 10, 14, 16, 17 et 876 s 5, 6 876 s 9, 10.11, 13, 14, 16.17, 18, 24, 27; et 877 s 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 25; et 878 o 7, 0, 10.11, 17, If et 881 s 8, 9, 10.11, 12.18, 20, 21; et 882 s 20, 21, 24, 26, 27, 28, 36.36, 37, 41, 42, 49, 52, 64, 66, 67.et 24; et 884 s 22 à 33 inclus et 61 à 61 inclus.15, 17, 20, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44.46, 48, 66, 67; et 885 s et 886 s 3, 4, 6, 7, 8.10.11, 12; et 887 s 2, 3; et 889 s 7, 8, 9, 12, 13 et 14.7, 8, 9 i.19, 26 883 s 5, 4, 7, et 214.88 177.42 129.98 69.95 464.77 12.58 245.93 1,096.85 11, 12, 13; et , 6-, et 880 e 7; 6, 7.8, 22, 23, 13 à 21 inclus; L'Espérance, André Suce.Moskaluk, Stefan.Pilarezik, Joseph.Robert, Pierre.Tellier, Moise Suce, ou inconnu a/s Alban-Majeau.Turcotte, Maurice.Ste- Julienne.19.80 20.50 20.00 34.80 52.11 144.17 24.97 4.05 141.43 Corporation municipale de la paroisse de St-Calixte \u2014 Municipal Corporation of St.Calixte Parish Noms et prénoms Names and surnames Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre Rang Range\tCanton Township\tTaxes munie.Munie, taxes\t\tTaxes scolaires School taxes\t\tFrais et intérêts Costs and int.\tTotal 1.\tKilkenney.\tS 54\t99\t$ 46\t45\t\t$ 101.44 1.\tKilkenney.\t103\t14\t\t\t\t103.14 2.\tKilkenney.\t22\t89\t4\t95\t\t27.84 2.\tKilkenney.\t25\t15\t5\t55\t\t30.70 2.\tKilkenney.\t40\t53\t6\t78\t\t47.31 2.\tKilkenney.\t74\t22\t11\t48\t\t85.70 2.\tKilkenney.\t63\t18\t110\t99\t\t174.17 2.\tKilkenney.\t45\t29\t37\t21\t\t82.50 2.\tKilkenney.\t10\t63\t10\t63\t\t21.16 2.\tKilkenney.\t39\t66\t29\t76\t\t69.41 3.\tKilkenney.\t157\t51\t197\t50\t\t355.01 3.\tKilkenney.\t140\t99\t13\t03\t\t154.02 3.\tKilkenney.\t19\t63\t2\t25\t\t21.88 3.\tKilkenney.\t42\t07\t7\t38\t\t49.45 3.\tKilkenney.\t40\t83\t7\t00\t\t47.83 3.\tKilkenney.\t192\t66\t197\t13\t\t389.69 3.\tKilkenney.\t\t\t66\t25\t\t66.25 3.\tKilkenney.\t42\t77\t42\t30\t\t85.07 3.\tKilkenney.\t64\t30\t10\t95\t\t75.25 4.\tKilkenney.\t65\t50\t46\t44\t\t101.94 4.\tKilkenney.\t70\t43\t11\t63\t\t82.06 4.\tKilkenney.\t102\t52\t127\t31\t\t229.83 4.\tKilkenney.\t76\t99\t68\t03\t\t145.02 4.\tKilkenney.\t56\t54\t45\t88\t\t102.42 5.\tKilkenney.\t82\t08\t\t\t\t82.08 5.\tKilkenney.\t26\t98\t16\t65\t\t43.63 5.\tKilkenney.\t13\t39\t8\t62\t\t22.01 6.\tKilkenney.\t10\t00\t9\t63\t\t19.63 6.\tKilkenney.\t16\t86\t\t\t\t16.85 5.\tKilkenney.\t22\t79\t1\t15\t\t23.94 6.\tKilkenney.\t11\t17\t10\t76\t\t21.93 5.\tKilkenney.\t10\t00\t8\t85\t\t18.85 5.\tKilkenney.\t90\t62\t\t\t\t90.62 6.\tKilkenney.\t10\t63\t\t\t\t10.63 Claire chamberland Gascon.St-Germain, Ernest.Fontaine, Jacqueline Varin.Fontaine, Jacqueline Varin.Fontaine, Marcel.Bureau, Fernand.Dorais, Vve René.Riccuito, Alfred.Riccuito, Alfred.Laurent, Gilbert.Lalonde, Adrien.Lacombe, Geo Aimé.Lacombe, Geo Aimé.Guy, Jean.Gagné, Roland.Boudreau, Gilles.Crédit Duvernay Inc.Young, Robert.Demontigny, Real.Bernard, Marcel.Massé, Real.Goulet, Claudette.Robichaud, Léonard.Couture, Maurice.Gaudreau, Aldège & Ux.Beaudoin, Roger.Beaudoin, Roger & Ux.DaPonte, Antonio.Madarasz, Itsvan.Fried, Andrew.Laslow, Horvath.Borla8 ou Borbas, Elizabeth.Lamoureux, Jacques D.Lamouroux.Dme Jacques D.P.9A.P.8c.P.11Aet 11c.P.11c.P.11A et 11c.P.12.P.12.P.12.P.12.P.12.10As 19.lib s 668, 669.libs 670.P.lib.P.lib.P.11c.P.11c.P.11c.12 s 14.P.9d & P.10A.P.10c.P.15A.P.20c.P.20d.P.9b.P.9b.P.9A.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a. 686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Corporation municipale de la paroisse de St-Calixte (suite) \u2014 Municipal Corporation of St.Calixte Parish (Continued) Noms et prénoms Names and surnames Budai.Leslie.Rover.Giovanni.Szelid, Imre.Langlois, Romuald.Vincent, Richard.Brosseau, Bernard.Boudreau, André.Michalkow S et Hedvig Stor-mer.Riendcau, Robert.Meunier.Dme Marcel.Landry, Jean-Paul.Bérubé, Jean-Paul.Rochon, Raymond.Rochon, Raymond.Légaré, Pauline.Boisvert, Marc.Sakalosky, Jeanne.Lauzon, Jean-Pierre & Maurice.Paquette, Dme René.Cantin, Claude.Perron, Normand.Rioux.André.Labontô, Léon.Labonté, Léon.Théoret, Armand.Girard, Gaston.Gérard, Roland.Gérard, Roland.Protasow, Alex.Paccito, Sylvio.Scardere, Alfred.Scardere, Alfred.Scardere, Alfred.Bergeron, Jean.Summerside, Louis.Bibeau, Emilien.Daigneault, Huguette.Perron, Michel S.Cyr, Marie-Madeleine.Dagenais, Aldor.Dagenais, Aldor.Gendron, Marcel.Corbeil, Marcel.Dumas, Gérard ou Dumai.Langlois, Michel Watson____ Picard, Gérard.Sakalosky, Jeanne.Walden, Jolin.Bastien, Bruno.Bastien, Bruno.Richard, Arthur.Watson, Suce.John.Delamirande, Dme J.Ls & Al Laporte.Emile.Bélair.Hervé.Club Sky nautique du Lac Connolly Inc.Laporte,Rodrigue.Bourque, Gerry.Duchesne, Dme Marie CM.Thinel, Dme Lucienne.Labrosse, André.Désormeaux, Florian.Daigneault.Arthur.Lavallée, Rosaire.De La Penna Dominico.Les Ent.Décarie Inc.Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P 10A.P.10a.P.HE.P.HE.13A s 10.13As 17.P.17a.P.17a.P.17c.P.17a.\".P.17c.P.18a.P.18a.P.18a.P.18a.P.18a.P.18c.P.18c.P.20b.P.20b.P.28a.P.28a.,.P.27a et P.25a.P.28a.P.28a.la, lb & lc.4a s L9____.P.5b____.P.6b.P.6b rang et lot 6c.P.8b.P.8d.P.8d.P.8d.P.8d.P.9a.10a s 3.P.13b.P.16b.P.10A.P.10a.P.10a.P.10a.P.21a.P.27.P.27.P.27.29a s P.2.29a s 46 à 49 et s 54 & 58.29a s 61.P.29b.P.29b.P.29b.P.30.P.29b.P.12a.12a s 72.14b-14c-14e-14i.Rang Range 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.6.5.5.5.5.5.5.5.6.6.5.\tTaxes\tTaxes Canton\tmunie.\tscolaires Township\tMunie.\tSchool \ttaxes\ttaxes Kilkenney.\tt 16.66\t$ 16.68 Kilkenney.\t37.76\t3.65 Kilkenney.\t83.97\t127.96 Kilkenney.\t56.48\t76.47 Kilkenney.\t19.80\t19.18 Kilkenney.\t22.14\t15.90 Kilkenney.\t56.31\t36.18 Kilkenney.\t34.98\t Kilkenney.\t12.25\t16.80 Kilkenney.\t210.41\t Kilkenney.\t44.26\t67.20 Kilkenney.\t21.62\t Kilkenney.\t12.57\t22.94 Kilkenney.\t40.80\t61.23 Kilkenney.\t11.43\t10.50 Kilkenney.\t11.17\t Kilkenney.\t11.17\t1.25 Kilkenney.\t67.65\t10.80 Kilkenney.\t11.17\t10.45 Kilkenney.\t11.03\t2.25 Kilkenney.\t11.17\t13.04 Kilkenney.\t77.50\t107.08 Kjlkenney.\t5.91\t Kilkenney.\t10.67\t5.05 Kilkenney.\t15.64\t27.70 Kilkenney.\t123.92\t92.52 Kilkenney.\t8.98\t8.62 Kilkenney.\t38.13\t30.40 Kilkenney.\t82.60\t69.65 Kilkenney.\t11.55\t1.48 Kilkenney.\t40.29\t64.20 Kilkenney.\t254.90\t371.67 Kilkenney.\t26.30\t111.81 Kilkenney.\t57.04\t55.30 Kilkenney.\t60.88\t57.53 Kilkenney.\t139.68\t95.66 Kilkenney.\t63.41\t Kilkenney.\t55.31\t46.96 Kilkenney.\t49.38\t8.18 Kilkenney.\t121.84\t148.79 Kilkenney.\t83.12\t222.88 Kilkenney.\t82.10\t14.38 Kilkenney.\t178.02\t162.45 Kilkenney.\t120.96\t11.18 Kilkenney.\t48.86\t40.40 Kilkenney.\t24.01\t29.85 Kilkenney.\t23.82\t24.53 Kilkenney.\t35.87\t67.16 Kilkenney.\t56.02\t47.45 Kilkenney.\t48.35\t29.88 Kilkenney.\t35.26\t49.61 Kilkenney.\t26.88\t5.23 Kilkenney.\t125.18\t20.78 Kilkenney.\t19.06\t10.28 Kilkenney.\t170.06\t Kilkenney.\t150.91\t20.46 Kilkenney.\t650.44\t161.91 Kilkenney.\t62.72\t30.15 Kilkenney.\t104.57\t110.54 Kilkenney.\t44.77\t4.20 Kilkenney.\t86.69\t Kilkenney.\t21.26\t Kilkenney.\t90.84\t12.83 Kilkenney.\t126.31\t178.20 Kilkenney.\t83.89\t16.63 Kilkenney.\t160.87\t128.26 Frais et intérêts Costs and in t QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 687 Corporation municipale de la paroisse de St-Calixte (suite) \u2014 Municipal Corporation of St.Calixte Parish (.continued) Noms et prénoms Names and surnames Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre \t\tTaxes\tTaxes\tFrais et\t Rang\tCanton\tmunie.\tscolaires\tintérêts\t \t\t\t\t\tTotal Range\tTownship\tMunie.\tSchool\tCosts\t \t\ttaxes\ttaxes\tand int.\t 9.\tKilkenney.\t$ 39.66\tS 60.24\t\tI 99.90 9.\tKilkenney.\t113.42\t10.20\t\t123.62 9.\tKilkenney.\t74.94\t12.48\t\t87.42 9.\tKilkenney.\t47.33\t38.88\t\t86.21 9.\tKilkenney.\t99.17\t114.05\t\t213.22 9.\tKilkenney.\t66.24\t1.98\t\t68.22 9.\tKilkenney.\t11.32\t16.88\t\t28.20 9.\tKilkenney.\t13.59\t\t\t13.59 9.\tKilkenney.\t49.33\t24.38\t\t73.71 9.\tKilkenney.\t18.76\t0.50\t\t28.26 9\tKilkenney.\t46.60\t18.70\t\t65.20 9.\tKilkenney.\t110.06\t96.10\t\t206.16 9\tKilkenney.\t126.71\t112.22\t\t238.93 9.\tKilkenney.\t12.57\t\t\t12.57 9.\tKilkenney.\t74.81\t58.92\t\t133.73 9.\tKilkenney.\t11.55\t21.20\t\t32.75 9.\tKilkenney.\t78.27\t112.81\t\t191.08 9.\tKilkenney.\t82.10\t174.24\t\t256.34 9.\tKilkenney.\t43.24\t4.13\t\t47.37 9.\tKilkenney.\t107.71\t114.01\t\t221.72 9\tKilkenney.\t63.42\t\t\t53.42 10.\tKilkenney.\t33.52\t\t\t33.52 10\tKilkenney.\t31.48\t\t\t31.48 10.\tKilkenney.\t81.58\t72.00\t\t153.58 10.\tKilkenney.\t61.65\t63.17\t\t114.82 10.\tKilkenney.\t55.47\t\t\t65.47 10\tKilkenney.\t42.73\t34.37\t\t77.10 10\tKilkenney.\t37.41\t32.50\t\t69.91 XI____\tKilkenney.\t117.76\t101.77\t\t219.53 XI____\tKilkenney.\t81.08\t71.53\t\t152.61 XI.\tKilkenney.\t118.91\t207.42\t\t326.33 XI____\tKilkenney.\t87.71\t15.45\t\t103.16 XI____\tKilkenney.\t124.67\t111.31\t\t235.98 XI____\tKilkenney.\t19.82\t\t\t19.82 XI____\tKilkenney.\t56.32\t27.71\t\t84.03 XI____\tKilkenney.\t48.45\t38.60\t\t87.05 XI____\tKilkenney.\t70.24\t12 86\t\t83.10 XI____\tKilkenney.\t12.88\t2.90\t\t15.78 XI____\tKilkenney.\t13.58\t18.43\t\t32.01 XI____\tKilkenney.\t112.04\t17.74\t\t129.78 XI____\tKilkenney.\t11.03\t\t\t11.03 XI____\tKilkenney.\t57.00\t155.34\t\t212.34 XI____\tKilkenney.\t66.76\t11.48\t\t78.24 XI____\tKilkenney.\t66.76\t\t\t66.76 XI____\tKilkenney.\t23.53\t22.77\t\t46.30 XI.\tKilkenney.\t72.06\t1.24\t\t73.30 XI____\tKilkenney.\t103.05\t22.46\t\t125.61 XI-\tKilkenney.\t90.28\t80.42\t\t170.70 XI____\tKilkenney.\t93.85\t87.37\t\t181.22 XI____\tKilkenney.\t112.29\t10.20\t\t122.49 XI____\tKilkenney.\t22.27\t4.35\t\t26.62 XI____\tKilkenney.\t11.03\t10.45\t\t21.48 XI____\tKilkenney.\t32.00\t\t\t32,00 XI____\tKilkenney.\t118.14\t128.35\t\t246.49 XI.\tKilkenney.\t24.48\t23.73\t\t48.21 XI____\tKilkenney.\t37.11\t\t\t37.11 XI____\tKilkenney.\t20.66\t\t\t20.66 Lévesque.Dme Delphis.Bi8aillon, Guy.Fournier, Josaphat.Tessier, Georges.Smith, Stanley.Konta, Marguerite.Carrier, Robert.Laprise, Jean-Guy.Bouchard, Gaston.Duchesne.Dme Pierrette.Guillet, Jeannette.Addy, Norbert.Addy, Norbert.Prévost, Ludger.Proulx, Gloria Kenny.Bisson, Bulite.Bi8aillon, Raymond.Gauthier, Jacques.Beaudet, Simone.Leroux, Claude.Patry, Claude.Hoyos.Camille & Zajdman A.Hoyos, Camille.Marie Rose Gagné Villeneuve Emard, Hubert.Therrien, Dme Jean.Lecompte, J.P.Léonard, Claude.Houle, Armand.L'Heureux, Jacques.Laf ranee, Dme Jean-Paul.Lanouette, Lucien.Dajerling, Hans J.& U.Lapalme, Jean-Paul.Poirier, Denis Maurice.Desjardins, Yvan.Laxson, Vve Françoise.Laxson, Vve Françoise.Stanley, Murray.Wendell Simpson & Ux et Heapy Arthur.Provost, Suce, a/s Monique & Marcel Provost.Kinsella, Edward.Davies, Douglass.Parent, Roger.Cartier, René.Bourque, Dme Jacques.Derepentigny, Claude Phi & Rosaire.Lambert, Guy.Hébert, Jean-Louis.Messier, Yvon.Taillon, Jean-Marc.Grégoire.Réjean.Bralant, Gérard.Beaudrv, Mlle Marie.Laporte, Richard.Linchet, Léon.Renard, Alphonse.P.12a.P.Ho.P.12a.12b s 7, 8.12b a 202.12b s 102.P.13a.P.14a.P.14a.P.14a.P.14a.P.14a.P.14a.P.14a.P.14a.P.15b.P.15a.P.15c et P.15d.P.15c et P.15d.P.15d.17c s 317.P.10a.P 9b.P.10a.P.12a.P.12a.P.12b.P.13c.P.3.P 3.4 s 163.164.165.5a 8 15 & 16-1.5a s 93.5b s 183, 184, 5ds220.5b s 236 & 237.5c s 64 et 5d s 293.5c s 85, 90, 92 & 95.5c s 86 & 89.5d s 283.5c 8 98, 101.5c s 117.5da235.5d 8 352.P.7c.P.8.P.8.P.8.P.8.P.8.P.8.P.8.9b s 25.P.10a.P.10a.P.14a.P.13c.P.14a.Corporation municipale de la paroisse de St-Donat \u2014 Municipal corporation of St.Donat Parish Atzi, Joseph.Ares, Clovi3.-.Bisonnette, Marie et Me Robert Dulude.P.19 P.40 P.34 c.\t 4.\t 4.\t \t S 21.36 35.17 6.54 $ 32.02 10.38 688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 89 janvier 1978, 10k' année, n° k Corporation municipale de la paroisse de St-Donat (suite) \u2014 Municipal corporation of St^Donat Parish (continued) Noms et prénoms\tNuméro du lot et du cadastre\tRang\tCanton\tTaxes munie.\t\tTaxes scolaires\t\tFrais et intérêts\tTotal Names and surnames\tNumber of lot and cadastre\tRange\tTownship\tMunie, taxes\t\tSchool taxes\t\tCosts and int.\t \t\t5.\t\t$ 42\t98\tS 29 29\t13\t\t$ 72.11 \t\t5.\t\t20\t20\t\t13\t\t49.33 \tP.b-1.\t1.\tLussier.\t64\t47\t84\t42\t\t148.89 De Tonnancourt, G.G.\t18.\t1.\tLussier.\t87\t58\t139\t28\t\t226.86 \t\t4.\t\t3\t80\t5\t18\t\t8.98 \tP.27.\tBloc G\t\t182\t87\t\t\t\t182.87 \tP.21-1.\t3.\tLussier.\t320\t70\t379\t04\t\t699.74 \t\t3.\tLussier.\til\t18\t21\t63\t\t32.81 \t28-2-41.\t3.\t\t10\t37\t21\t63\t\t32.00 \t38-76.\t3.\tLussier.\t94 SI 76\t92 15 43\t\t\t\t94.92 51.15 262.69 Monp;iin.Michel.\t7.\tC\tLussier.\t\t\t186\t26\t\t \t12.:.\tBloc E.\tLussier.\t125\t14\t134\t46\t\t259.60 \t\td.\tLussier.\t282\t38\t685\t83\t\t967.71 Semeredy, Michela Arthur.\t\tBloc G.\t\t252\t27\t333\t26\t\t585.53 \t40.\tBloc F.\tLussier.\t\t\t102\t86\t\t102.86 \t41-20.\t4.\tLussier.\t23\t54\t25\t92\t\t49.46 Poissant J M .\t\t3.\t\t3\t42\t18\t67\t\t21.99 \t41-2-9.\t3.\tLussier.\t7\t52\t\t\t\t7.62 \t41-2-17.\t3.\tLussier.\t7\t52\t\t\t\t7.52 Poissant, J.M.Poissant J M .\t41-2-27.\t3.\t\t7\t52\t\t\t\t7,52 \t41-13 .\t4.\t\t7\t52\t\t\t\t7.62 Asselin, Dme Emile.\tP.1.\t6.\tArchambault\t24\t04\t\t\t\t24.04 \tP.2.\t0.\tArchambault\t41\t69\t\t\t\t41.69 \tP.30.\t1.\tArchambault\t80\t39\t\t\t\t80.39 \tP.30.\t1.\tArchambault\t207\t76\t452\tS7\t\t660.63 Martin, Jean Marc.\tP.31.\t1.\tArchambault\t52\t82\t\t\t\t52.82 Morin Dme Carmel Boutin.\tP.31.\t1.\tArchambault\t88\t55\t\t\t\t88.55 Parent, Dme André.\tP.10-C.\t3.\tArchambault Archambault\t30 48\t53 29\t30 61\t27 18\t\t60.80 109.47 Villeneuve, Georges.\tP.10-C.\t3.\t\t\t\t\t\t\t Corporation municipale de la paroisse d'Entrelacs \u2014 Municipal corporation of Entrelacs Parish Archambault, Oscar.Demers, Dme Armand .Hogue, Dme Denise.Redfern.Georges.Duclos, Dme Anita,.Drouin, Melle Marcel- St Onge, Viateur.St Onge, Viateur.Trudel, Jean-Jacques.Logée, O.Couroy, Yvon.Sweeney, James.Sweeney, James.Scardere, Alfred.Sénécal.Robert.Cloutier.Jean-Marc.Sauvé.Roger.Portelance, Charles.Duval, Florent.Deschâtelels, Jérôme.Perreault, Mario & Gilles Riopel, Vve Roméo.Théoret.Melle Micheline 44 s 3, 4.7, P.10, 20, 20-4,\t10.\tWexford.\t$ 645.12\tS 505.68\t 20-5, 20-6.\t\t\t\t\t P.10.\tS Ch.\tChertsey.\t14.00\t0.59\t P.59.\t8 W.\tWexford.\t167.86\t\t P.47.\t10 W.\tWexford.\t22.41\t23.16\t P.6.\t8 ch.\tChertsey.\t96.75\t471.18\t P.7a.\t9 ch.\tChertsey.\t80.34\t\t 44-12.\t10 W.\tWexford.\t90.75\t109.64\t 44-18.\t10 W.\tWexford.\t85.55\t148.01\t P.57.\t8 W.\tWexford.\t89.90\t148.81\t P.2.\t8 ch.\tChertsey.\t49.12\t147.05\t P.8a.\t9 ch.\tChertsey.\t33.42\t63.79\t P.56.\t9 W.\tWexford.\t10.81\t12.57\t P.66.\t9 W.\tWexford.\t8.04\t21.31\t P.48.\t10 W.\tWexford.\t20.10\t32.70\t P.5 et P.6.\t7 ch.,.\tChertsey.\t133.84\t137.05\t P.10.\t8 ch.\tChertsey.\t18.41\t19.43\t P.48.\t10 W.\tWexford.\t668.32\t\t P.44.\t8 W.\tWexford.\t40.00\t103.46\t P.2.\t8 ch.\tChertsey.\t97.56\t105.51\t P.2.\t9 ch.\tChertsey.\t56.67\t67.82\t P.64.\t7 W.\tWexford.\t50.96\t99.44\t 44.\tXI W.\tWexford.\t46.32\t\t P.53.\t9 W.\tWexford.\t59.34\t181.41\t Corporation municipale du village de Rawdon \u2014 Municipal corporation of the village of Rawdon Barrie, Ernest.Daly, Robert.DeNotto, Dme I Legault, Eugène.18F 2.17-33-1.16C-43.19-58-2 & 3 6 6 e 8 Rawdon.Rawdon.Rawdon.Rawdon.$ 26.13 22.76 8.30 22.38 64.33 19.80 83.26 6.10 2.95 11.90 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.4 689 Corporation municipale du village de Rawdon (suite) \u2014 Municipal corporation of the village of Rawdon (continued) \tNuméro du lot\t\t\tTaxes\tTaxes\tFrais et\t Noms et prénoms\tet du cadastre\tRang\tCanton\tmunie.\tscolaires\tintérêts\t \t\t\t\t\t\t\tTotal Names and surnames\tNumber of lot\tRange\tTownship\tMunie.\tSchool\tCosts\t \tand cadastre\t\t\ttaxes\ttaxes\tand int.\t \t18A s 273, 274, 275\t6\tRawdon.Rawdon____ Rawdon.Rawdon.Rawdon.\tS 98.13 1.40 65.60 187.43 70.48\tS 189.12 89.55 346.96 153.45 47.25\tS 19.15 12.71 28.80 31.09 11.00\tS 306.40 103.66 441.36 371.97 128.73 Masse, Dme J.Emile.\t19-49-3.\t6____\t\t\t\t\t Sheehan, Patrick.\t17-107-2.\t5.\t\t\t\t\t \t18b- 37-3.\t6.\t\t\t\t\t \t18A s P.325____\t6.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Donné à Sainte-Julienne, ce 5e jour de janvier 1972.43918-2-2-o Le secrétaire du Conseil du Comté, Henri Dcpuis.Given at Sainte-Julienne, this 5th day of January 1972.Henri Dupuis, 43918-2-2-0 Secretary of Council.Municipalité du Comté de Laprairie Je, soussigné, Gérard Péladeau, secrétaire-trésorier de la Corporation du Comté de Laprairie, donne avis, par les présentes, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l'enchère publique, au lieu où le Conseil de Comté tient ses Sessions, en la Ville de Laprairie, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures du matin, à défaut de paiement des taxes auxquelles ils sont affectés et des frais encourus pour la vente.Municipality of the County of Laprairie I, the undersigned, Gérard Péladeau, Secretary-Treasurer of the Corporation of the County of Laprairie, hereby give notice that the immoveables hereunder described will be sold by public auction, at the place where the sittings of the County Council are held, in the Town of Laprairie, on THURSDAY, the NINTH day of MARCH 1972, at TEN o'clock in the forenoon in default of payment of the taxes for which they are liable and the costs incurred for the sale.Ville de Laprairie \u2014 Town of Laprairie (Commission scolaire de la Ville de Laprairie) \u2014 (Laprairie School Board) Cadastre paroisse de Laprairie \u2014 Cadastre parish of Laprairie \tLots\t\tTaxes\t\tTaxes\t\tTaxes\t\t Propriétaire\tNos\t\t8C0l.\t\tprot.\t\tmun.\t\t \t\tCadastre\t\tInt.\t\tInt.\t\tInt.\tTotal Proprietor\tLots\t\tSchool\t\tProt.\t\tMun.\t\t \tNos\t\ttaxes\t\ttaxes\t\ttaxes\t\t \t\tP.344.\t$ 992.19\t$102.35\t$ 7.16\t$ 0.08\t$498.6S\t$ 53.95\t$1.654.41 \t\tP.203.\t1,329.36\t124.34\t\t\t120.00\t3.46\t1.577.16 \t\tP.202\t1,093.32\t107.94\t\t\t775.20\t\t \t\t\t\t\t\t\t100.00\t2.71\t2.130.93 \t\t35.\t382.80\t37.21\t\t\t243.30\t26.31\t \t\t\t\t\t\t\t230.00\t18.66\t938.28 \t3.\t364.\t229.05\t27.98\t\t\t102.00\t11.04\t370.07 \t\tP.364.\t455.55\t48.59\t\t\t106.50\t6.55\t617.19 \t533.\t673.\t531.97\t49.10\t\t\t169.10\t11.00\t \t\t\t\t\t\t\t77.10\t2.35\t840.62 \t69.\t539.\t17.91\t1.49\t\t\t17.03\t1.19\t37.62 \t70\t539.\t17.91\t1.49\t\t\t\t\t19.40 \t71.\t539.\t12.06\t1.00\t\t\t\t\t13.06 \t72.\t639.\t12.05\t1.00\t\t\t\t\t13.05 \t71\t492.\t23.08\t2.07\t\t\t\t\t25.15 \t216.\t492.\t33.93\t2.94\t\t\t\t\t36.87 \t65\t539.\t17.94\t1.46\t\t\t\t\t19.40 \t79\t492.\t23.42\t2:12\t\t\t9.00\t0.98\t35.53 \t\t\t\t\t\t\t\t\t 690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i- année, »3 i Ville de Brossard \u2014 Town of Brosaard (Commission scolaire de Brossard) \u2014 (Brossard School Board) Cadastre paroisse de Laprairie \u2014 Cadastre parish of Laprairie \t\tTaxes\t Taxes\tTaxes\tscolaires\t munie.\tscolaires\tprotest.\tTotal Munie.\tSchool\tProtest.\t taxes\ttaxes\tschool\t \t\ttaxes\t \tS 174.42\t\t$ 174.42 \t15.70\t\t16.70 \t370.35\t\t370.35 356.93\t265.05\t\t621.98 \t499.95\t\t499.95 \t17.82\t\t17.82 \t103.00\t\t103.00 \t79.74\t\t79.74 297.01\t66.95\t\t363.96 \t333.00\t\t333.00 \t523.80\t\t523.80 26.90\t558.00\t\t584.90 234.59\t21.67\tS 4.54\t260.80 \t181.80\t\t181.80 \t89.18\t\t89.18 \t10.80\t\t10.80 \t255.60\t\t255.60 \t18.31\t\t18.31 432.03\t393.30\t\t825.33 \t285.30\t\t285.30 \t\t5.91\t6.91 276.22\t31.77\t\t307.99 373.94\t13.95\t\t387.39 \t85.95\t\t85.95 262.87\t24.66\t6.54\t294.07 262.87\t24.66\t\t287.53 262.87\t24.66\t6.54\t294.07 254.48\t23.17\t6.18\t283.83 400.01\t142.69\t2.20\t544.90 251.32\t23.53\t6.26\t281.11 251.32\t23.53\t46.92\t321.77 296.52\t18.31\t\t314.83 \t285.30\t\t285.30 \t11.59\t\t11.59 \t19.43\t\t19.43 268.56\t24.66\t6.54\t299.76 246.33\t46.31\t12.26\t304.90 290.88\t34.74\t\t325.62 233.51\t31.37\t8.35\t273.23 275.74\t32.87\t8.71\t317.32 218.37\t155.70\t\t374.07 \t4.95\t\t4.95 \t288.08\t\t288.08 \t13.50\t\t13.50 \t14.40\t\t14.40 \t13.95\t\t13.95 \t7.68\t\t7.68 228.38\t19.04\t5.08\t252.50 15.99\t34.20\t\t50.19 325.07\t82.80\t\t407.87 324.69\t82.80\t\t407.49 196.02\t31.06\t\t227.07 403.42\t97.11\t\t500.53 403.42\t97.11\t\t500.53 403.42\t97.11\t\t500.53 403,42\t97.11\t\t500.63 417.06\t25.78\t\t442.84 404.83\t24.28\t\t429.11 Nom du propriétaire Name of proprietor Horvath, Tibor.Charbonneau, A.Roger.Boulanger, Patrick.Caluori, Georges.Tremblay, J.-Marc.Boisvert, Gérard.St-Araand, Roméo.Guertin, Georges.Bédard, Raymond.Bouchard, Albert.Hébert, Réjean.Leblanc, André.Démontigny, Gérard.Brière, Émue.Babin.Jean-Marie.Long.Robert.Lefebvre, Raymond.Fontaine.Guy.\u2022Godbout, Ronald.Latour.Henri, Mme A- Allaire, J.-Ronald.Lavoie, Lucien.Perks, Ronald A.Bernier, Gabriel.Jurjo Miguel Angel.Lemaire, Guy.Von Kafalvy, Anna Marie Robert, Gilles.Duff Tyler, Charles-J.Boucher, Serge.Murray, Marie-France.Szczepkowski, Walter.Was.Joseph.Danilov, Stephen J.Allessandrini A., (P.16A), rang quatre (R.4), du canton de Hull, connu comme la subdivision non officielle numéro trois (16A-3 non off.) mesurant cent cinquante pieds de largeur (150') par deux cent quatre-vingt-treize pieds (293') de profondeur, plus ou moins, mesures anglaises, bornée comme suit: au nord par le Chemin Pink: à l'est par partie dudit lot seize \u2022 A > (P.16A) connue comme la subdivision non-officielle numéro deux, propriété de Monsieur Louis Laflamme ou représentants; au sud par partie du lot seize \u2022 A > (P.16A) connue comme la subdivision non officielle quinze (15), propriété de Beverley Shoul-dice ou représentants; à l'ouest par partie du lot seize « A » (P.16A), connue comme la subdivision non officielle quatre (4), propriété de Monsieur Antoine Lacourcière ou représentants; avec tous les bâtiments y dessus érigés, circonstances et dépendances.Aylmer Park Development P.19.Glenwood Shopping Plaza.Cette partie du lot 19 non subdivisé, commençant à un point situé au coin nord-ouest du lot 19-455, sur la ligne separative entre la ville d'Aylmer et le canton de Hull, de là, vers l'est le long de la limite nord du lot 19-455, une distance de cent trente-quatre pieds et trois dixièmes d'un pied (134.3') à un point; de là, vers le nord et parallèlement à la ligne separative entre la ville d'Aylmer et le canton de Hull, une distance de trente-quatre pieds (34') à un point; de là, vers l'ouest, et parallèlement à la limite nord du lot 19-455, une An immoveable situated in the township of Hull, province of Québec, County of Oatineau, known and designated as being the lots number one hundred twenty-one, one hundred twenty-two, one hundred twenty-three, one hundred twenty-four and the half south of lot number one hundred twenty-five of the official subdivision lot number sixteen \"D\" (16D-121, 122, 123, 124-HS-125) in the range one (R.1) on the official plan and book of reference of the Township of Hull, the said half south more particularly described and bounded as follow: to the east by Maple Grove; to the south by lot 16D-124, to the west by the subdivision primitive lot number 17A; and to the north by the north half of the said lot number 16D-125.As the whole now exists and with building thereon erected, members and appurtenances.5 5.00 292.72 297.72 An immoveable known and designated as being the southeast corner of lot seventeen \"B\" (17B) in range five (R.5) on the official plan and book of referencet for the_ township of Hull, measuring eighty-two feet (82') in width on its north and south boundaries by one hundred and thirty-two feet (132') in depth on its east and west boundaries, bounded as follows: On the north by part of lot seventeen \"B\" (P.17B), belonging to Sifton P.McClelland or representatives, on the east by Vanier Avenue, on the south by Pink Road and on the west by part of lot seventeen \"B\" (P.17B) property of Sifton P.McClelland or representatives; with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.4 219.98 508.60 728.58 An immoveable situated in the township of Hull, being a part of lot sixteen \"A\" (P.16A), range four (R.4), in the township of Hull, known as the non-official subdivision number three (16A-3 non-off.) measuring one hundred and fifty feet (150') in width by two hundred and ninety-three feet (293') in depth, more or less, English measure, bounded as follows: On the north by the Pink Road ; on the east by part of the said lot sixteen \"A\" (P.16A) known as the non-official subdivision number two.property of Mr.Louis Laflamme or representatives; on the south by part of lot sixteen \"A\" (P.16A) known as the non-official subdivision fifteen (15), property of Beverley Shouldice or representatives; on the west by part of lot sixteen \"A\" (P.16A) known as the non-official subdivision tour (4), property of Mr.Antoine Lacourcière or représentatives; with all buildings thereon erected, circumstances and dependencies.25.69 59.46 85.15 That unsubdivided part of lot 19, starting at a point situated at the northwest corner of lot 19-455, along the dividing line between the town of Aylmer and the township of Hull, thence eastward along the northern boundary of lot 19-465, a distance of one hundred and thirty-four and three tenths feet (134.3') to a point; thence, northward and parallel to the dividing line between the town of Aylmer and the township of Hull, a distance of thirty-four feet (34') to a point; thence, westward, and parallel to, the northern boundary of lot 19-455.a distance QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 775 distance de cent trente-quatre pieds et trois dixièmes d'un pied (134.3') à un point; de là, vers le sud, le long de la ligne separative entre la ville d'Aylmer et le canton de Hull, une distance de trente-quatre pieds (34') jusqu'au point de départ.of one hundred and thirty-four and three tenths feet (134.3') to a point; thence, southward, along the dividing line between the town of Aylmer and the township of Hull, on a distance of thirty-four feet (34') to the point of commencement.Taxes Taxes Noms Rang munie.scol.Lots Total Names Range Munie.School taxes taxes Aylmer Park Development Glenwood Shopping Plaza.Un certain morceau ou une certaine parcelle de terrain connu comme étant la partie nord de la demie ouest du lot 2016 au cadastre officiel de la ville d'Aylmer, mesurant 850 pieds (850') de largeur sur ses lignes nord et sud, par neuf cent pieds (900') de profondeur sur ses lignes est et ouest, mesure anglaise et comprenant une superficie totale de 76,500 pieds carrés, et borné comme suit: A une extrémité, au nord, par le terrain du canton de Hull sur un côté, à l'est, par une partie de la moitié est du lot 2016, à l'arrière, au sud, par la partie restante de la moitié ouest du même lot, appartenant au vendeur ou représentants, et sur l'autre côté, à l'ouest, par le lot 2070 du même cadastre.Aylmer Park Development, P.19-294-5.Glenwood Shopping Plaza.Le lot 19-294-5, moins cette partie vendue en février 1962 à Glenwood Water Services; superficie d'environ 77 acres.Aylmer Park Development, P.17B.Glenwood Shopping Plaza.Un immeuble situé dans le canton de Hull, comté de Gatineau, province de Québec, comprenant toute cette propriété désignée comme étant un terrain en une seule pièce de configuration irrégulière, étant formé de partie du lot dix-sept « B » (P.17B) dans le rang un dudit canton de Hull, selon les plan et livre de renvoi officiels dudit canton, comté de Gatineau, province de Québec et plus particulièrement décrit comme suit: Commençant à un point indiqué par la lettre « A > sur le plan préparé par Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre de Québec, numéro 151, daté à Hull, le 14 juin 1956, copie dudit plan étant demeurée annexée au contrat original enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Gatineau, sous le numéro 40S77, le 24 novembre 1956; lequel point « A > étant sur la ligne de division entre les lots 17B et 18A desdits rang et canton et à l'intersection de la limite sud du terrain appartenant à la compagnie de Chemins de Fer du Canadien Pacifique ou ses mandataires; à partir dudit point de départ, quatre-vingt-huit degrés nord, trente-cinq minutes est (N.88° 35' E.) une distance de deux cent quatorze pieds et sept dixièmes de pied (214.7') plus ou moins jusqu'au point « B », quatre-vingt-six degrés en direction nord, cinquante-trois minutes est (N.86° 53' E.), une distance de trois cent quatre vingt-dix-neuf pieds (399') plus ou moins jusqu'au point « C >; du point « C » en direction nord quatre-vingt-deux degrés, quarante-neuf minutes est, du point « D » vers le sud six degrés, dix minutes est (S.6° 10' E.) une distance de cinq cent quatre-vingt-dix pieds et quatre centièmes de pied (590.04') plus ou moins jusqu'au point «E»; dudit point « E > vers le nord quatre-vingt-sept degrés, cinquante-quatre minutes ouest (N.87° 54' O.) une distance de quatre cent soixante-et-dix-huit pieds et deux dixièmes de pied (478.2') plus ou moins jusqu'au point « F »; dudit point « F » vers le sud deux degrés, treize minutes ouest (S.2° 13' O.) une distance de deux cent quatre-vingt-un pieds et neuf dixièmes (281.9') plus ou moins jusqu'au point «G»; dudit point « G » vers le sud quatre-vingt-sept degrés, cinquante-deux minutes ouest (S.87° 52' O.) une distance de cinquante pieds et un dixième de pied (50.1') plus ou moins jusqu'au point « H >; dudit point « H », vers le nord deux degrés, treize minutes est (N.2° 13' E.) une distance de deux cent quatre-vingt- P.O.-W.H 2016.Cad.$ 35.33 S 112.38 S 147.71 de-of ViUe-Town Aylmer.A certain piece or parcel of land known as being the north portion of the weet H °f lot 2016.official cadastre of the town of Aylmer, measuring 850 feet (850') in width in the northern and southern lines by nine hundred feet (900') in depth in its eastern and western lines, English measure, and containing a total superficie of 76,500 square feet, and being bounded as follows: At one end, to the north by the land of the township of Hull on one side, to the east part of the east half of lot 2016 in rear, to the south by the remaining portion of the west half of same lot, belonging to the vendor or representatives, and on the other side to the west by lot 2070 of the same cadastre.210.24 565.85 776.09 Lot 19-294-5, less that part sold February 1962 to Glenwood Water Services; approximate area: 77 acres.42.47 130.52 172.99 An immoveable situate in the township of Hull, county of Gatineau, Province of Québec, consisting in all that property designated as being all that singular piece of land of irregular figure being formed of part of lot seventeen \"B\" (P.17B) in the first range of said township of Hull, according to the official plan and book of reference of said township, county of Gatineau, Province of Québec and more particularly described as follows: Commencing at a point indicated by letter \"A\" on a plan prepared by Jean-Paul Alary, Québec Land Surveyor, number 151, dated at Hull, June 14, 1956, a copy of said plan remaining attached to the original deed registered at the Registry Office for the Gatineau County under number 40877, on November 24, 1956; which point \"A\" is on the divisional line between lots 17B and 18A of said range and township and its intersection with the southerly limit of the land belonging to the Canadian Pacific Railway Company or its assigns; from said commencing point, north eighty-eight degrees, thirty-five minutes east (N.88° 35' E.) a distance of two hundred and fourteen feet and seven tenths of a foot (214.7') more or less to point \"B\", in a direction north eighty-six degrees, fifty-three minutes east (N.86° 53' E.) a distance of three hundred and ninety-nine feet (399') more or less to point \"C\"; from point \"C\", in a direction north eighty-two degrees, forty-nine minutes east, from point \"D\" a distance south six degrees ten minutes east (S.6°, 10' E.) a distance of five hundred and ninety feet and four hundredths of a foot (590.04') more or less to point \"E\", from said point J'E\", in a direction north eighty-seven degrees, fifty-four minutes west (N.87° 54' W.) a distance of four hundred and seventy-eight feet and two tenths of a foot (478.2') more or less to point \"F\"; from said point \"F\" in a direction south two degrees, thirteen minutes west (S.2° 13' W.) a distance of two hundred and eighty-one feet and nine tenths of a foot (281.9') more or less to a point \"G\"; from said point \"G\" in a direction south eighty-seven degrees, fifty-two minutes west (S.87° 52' W.) a distance of fifty feet and one tenth of a foot (50.1') more or less to point \"H\"; from said point \"H\", in a direction north two degrees, thirteen minutes east (N.2° 13' E.) a distance of two hundred and eighty-five feet and six tenths of a foot (285.6') more or less to point \"I\" on said plan: from said point \"I\", in a direction 776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, m< année, n° k cinq pieds et six dixièmes de pied (285.60 plus ou moins jusqu'au point « I » sur ledit plan; dudit point « I », vers le sud soixante-neuf degrés, trente-six minutes ouest (S.69° 36' O.), une distance de trois cent cinquante-six pieds et huit dixièmes de pied (356.8') plus ou moins, jusqu'au point « J »; dudit point « J », vers le nord six degrés, trente-huit minutes ouest (N.6° 38' O.), une distance de six cent trente-etrun pieds et neuf dixièmes de pied (031.9') plus ou moins, jusqu'au point « A », étant le point de départ.Ladite parcelle de terrain étant bornée comme suit: vers le nord par une autre partie du même lot étant le droit de passage du C.R.R.; vers l'est par partie du lot 17A et du lot 17B; vers le sud parla rivère Ottawa et partie du lot 17B; vers l'ouest par partie des lots 17B et 18A, le tout contenant une superficie de onze acres et quarante-huit centièmes d'acre (11.48 a.) de terrain, plus ou moins.Toutes les mesures dans la présente description et sur le plan y mentionné sont des mesures anglaises et les directions sont astronomiques.La parcelle de terrain décrite ci-dessus est indiquée par» les lettres « A, B.C, D, E, F, G, H, I, J, A » et un contour jaune et vert sur le plan ci-haut mentionné.Le vendeur s'est réservé un droit de passage allant de l'est à l'ouest et de largeur suffisante afin de pouvoir traverser avec des véhicules ou autrement cette partie du lot 17B indiquée sur le plan ci-haut mentionné par les lettres- « I-H-G-F-I- », ledit droit de passace étant réservé en vue de l'élargissement éventuel de la route à l'arrière des lots ayant front sur le cours d'eau en partant du terminus actuel de la route afin de pouvoir rejoindre l'autre partie dudit lot 17B qui demeure la propriété de la venderesse, Dame Anna Foley, née Grondin, ou représentants, et se trouvant à l'ouest de lacùte lisière de terrain indiquée par les lettres « I-H-G-F-I » sur ledit plan i (P.160, appartenant à ladite Dame Agnes Smith, veuve dudit Andrew Latimer ou représentants.Avec servitude de droit de passage sur la propriété décrite en premier lieu, établi en vertu d'un acte de vente consenti par ladite Dame Agnes Smith, veuve dudit Robert Andrew Latimer à ladite Dame Roberta Latimer, devant Me André Lesage, notaire, le 29 mai 1962, sous le numéro 13,396 de ses minutes, enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Gatineau, le 5 juin 1962, sous le numéro 58,782.widow of the said Robert Andrew Latimer or assigns, towards the east by part of said lot sixteen \"C\" (P.16C), above described, towards the south by part of said lot sixteen \"C\" (P.16C), the property of the said Ormond Young or assigns and towards the west by part of said lot sixteen \"C\" (P.16C), the property of the said Dame Agnes Smith, widow of the said Andrew Latimer or assigns.\"With a right of way against the property firstly described established according to a deed of saje granted by the said Dame Agnes Smith, widow of the said Robert Andrew Latimer to the said Dame Roberta Latimer, before Mtre André Lesage, notary, on the 29th of May 1962, under number 13.396 of his records, registered at the Gatineau Division Registry Office, on the 5th, of June 1962, under number 58,782.Corporation de Northfield \u2014 Canton de Blake Corporation of Northfield \u2014 Township of Blake Taxes Taxes Noms Rang munie.scol.Lots Total Names Range Munie.School taxes taxes Phillips, William H., & Leclair, Henri.P.12 Toute cette propriété connue et désignée comme étant formée d'une partie du lot numéro 12 et peut-être d'une partie du lot numéro 13, rang 9, canton de Blake, plus amplement décrite comme suit: Partant à un point situé sur la rive du Lac Pemichangan au coin sud-est de la propriété telle que nommée C.W.Floyd Coffin, décrite et y référée dans un acte de vente consentie audit C.W.Floyd Coffin par Dame Priscille Caron, née Marier, veuve de Jérémie Caron, en date du 15 août 1938, et exécuté sous le numéro 14,586 du greffe de Henri DesRosiers, notaire, et enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Gatineau sous le numéro 4621.et ledit point de départ indiqué par un poteau marqué < A » déjà planté; de ce point dans une direction sud suivant la.rive dudit Lac Pemichangan, sur une distance de 420 pieds, plus ou moins, jusqu'à un point indiqué par un poteau marqué « B > déjà planté; de là, en suivant la rive du lac dans une direction nord-ouest, ouest et sud-ouest contournant une baie dudit lac jusqu'à un point indiqué par un poteau marqué « C » déjà planté; de là suivant la rive dudit lac dans une direction nord-ouest, ouest et sud-ouest contournant une baie dudit lac jusqu'au point indiqué par un poteau marqué « D » déjà planté, tel qu'élaboré sur ledit plan; de là, dans une direction nord-ouest par une ligne droite jusqu'à un chemin connu comme étant le chemin Coffin sur une distance de 200 pieds, plus ou moin.v jusqu'au point indiqué par un poteau marqué « E » déjà planté; de là dans une direction nord-est suivant ledit chemin connu comme étant le chemin Coffin sur une distance de 460 pieds, plus ou moins, jusqu'à un point sur le côté est dudit chemin Coffin indiqué par un poteau marqué « F » déjà planté, se trouvant à l'intersection de la limite sud de ladite propriété Coffin telle que décrite dans l'acte de vente référé ci-dessus, avec la limite est dudit chemin connu comme étant le chemin Coffin ; de là, vers l'est suivant la ligne sud de ladite propriété Coffin, tel que référé dans ledit acte de vente, sur une distance de 260 pieds jusqu'au point de départ; le tout borné comme suit: vers le nord par une autre partie des mêmes lots, la propriété dudit C.W.Floyd Coffin tel que référé dans ledit acte de vente, a l'ouest par le lac Pemichangan, au sud par le lac Pemichangan et par des baies formées dans ledit lac, au sud-ouest par une autre partie du même lot, la propriété du vendeur étant la ligne qui s'étend desdits poteaux « D » et « E » et au nord-ouest par le chemin connu comme étant le chemin Coffin.Comprenant un droit de passage pour les véhicules ou autrement afin de communiquer de la parcelle de terre décrite ci-deesus avec le ohemin public connu comme étant le chemin .9 S 22.60 S 89.66 % 112.06 cant.-towns.Blake.All that property known and designated as being formed of part of lot number 12 and may be part of lot number 13, range 9, township of Blake, more particularly described as follows: Commencing at a point situated on the shore of Pemichangan Lake at the southeasterly corner of the property of one named C.W.Floyd Coffin as described and referred to in a deed of sale granted to said C.W.Floyd Coffin by Dame Priscille Caron born-Marier, widow of Jérémie Caron, on the 16th August, 1938, and executed under number 14,586 of the repertory of Henri DesRosiers, notary, registered in the Gatineau Division Registry Office, under number 4621, and said starting point indicated by a postmarked \"A\" already planted; from that point in a southerly direction following the shore of said Pemichangan Lake, a distance of 420 feet more or less, to a point indicated by a post marked \"B\" already planted; thence, following the shore of the lake, in a northwesterly, westerly and southwesterly direction contouring a bay of the said lake to a point indicated by a post marked \"C\" already planted; thence, following the shore of the said lake in a northwesterly, westerly and southwesterly direction contouring a bay of the said lake to a point indicated by a post marked \"D\" already planted as shown on the said plan ; thence, in a northwesterly direction in a straight line to a road known as Coffin's road a distance of 200 feet more or less, to a point indicated by a post marked \"E\", already planted; thence, in a northeasterly direction following the said road known as Coffin's road a distance of 460 feet, more or less, to a point, on the easterly side of the said Coffin's road indicated by a post marked \"F\", already planted, being at the intersection of the southerly limit of said Coffin's property as referred to in the said deed of sale above referred to with the easterly limit of the said road known as Coffin's Road; thence, easterly following the southerly line of the said Coffin's property as referred to in the said deed of sale a distance of 260 feet to the starting point; the whole bounded as follows: Northerly by another part of the Bame lots, the property of said C.W.Floyd Coffin, as referred to in the said deed of sale, westerly by Pemichangan Lake, southerly by Pemichangan lake and by bays formed out of the said lake southwesterly by another part of the same lot, the property of the vendor being the line extending from said posts \"D\" and \"E\" and northwesterly by the road known sb Coffin's Road.Including a right of way for véhicules or otherwise to communicate from the parcel of land above described with the public road known as \" ( u Ton's Road\", the use of \"Coffin's 778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° k Caron, l'usage du chemin Coffin, tel qu'actuellement utilisé; et ledit usage du droit de passage comprend aussi le droit d'emprunter le chemin Caron conjointement avec tous les autres parties intéressés.Beaudry, Mme-Mrs.Bernard.P.15.Un immeuble situé dans le canton d'Eardley.Toute cette propriété connue et désignée comme étant formée d'une partie du lot quinze (P.15) du sixième rang (6), conformément aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton d'Eardley, ledit emplacement de forme irrégulière, étant situé au nord-est d'un chemin privé conduisant à la rivière Ottawa et plus particulièrement décrit comme suit: Commençant à un point situé au nord-est du chemin privé ci-dessus mentionné et coïncidant avec le coin nord-ouest de la propriété de Roland Duguay ou représentants, ainsi que décrit et limité selon les bornes dans un acte de vente exécuté devant Me Charles Munn, notaire, sous le numéro 276 de ses dossiers, dont une copie enregistrée au bureau d'enregistrement de Gatineau, à Maniwaki, sous le numéro 43-450; de là, dans une direction nord-ouest le long du côté nord-est dudit chemin privé, une distance de cent vingt-neuf pieds (129') jusqu'à un point; de là.dans une direction est.sur une distance de cent un pieds (101') jusqu'à un point situé sur la limite ouest de la propriété de Pierre Tremblay ou représentants; de là.dans une direction sud le long de la limite ouest de la propriété de Pierre Tremblay ou représentants, sur une distance de cent vingt-six pieds (126') jusqu'à un point situé au coin nord-est de la propriété dudit Roland Duguay ci-dessus désignée; de là, dans une direction ouest le long de la limite nord de la propriété dudit Roland Duguay, sur une distance de cent trente-sept pieds (137') de retour au point de départ.Ledit emplacement est indiqué par un poteau fixé à chaque coin et est borné comme suit: Vers l'ouest par un chemin privé; vers le nord par une autre partie du môme lot, propriété d'un M.Leduc ou représentants; vers l'est par une autre partie du même lot, propriété de Pierre Tremblay ou représentants et vers le sud par une autre partie du même lot, propriété de Roland Duguay ou représentants.Avec les bâtisses dessus érigées, membres et appartenances et droit de passage.Decelles, Raymond.P.3-12.Une certaine pièce ou parcelle de terrain formant partie du lot numéro trois (P.3) du deuxième rang, (R, 2), aux plan et livre de renvoi officiels du canton d'Eardley, non officiellement connu comme étant le lot numéro douze aux plan et livre de renvoi officiels dudit lot numéro trois (3-12), plus particulièrement décrit comme suit: Commençant à un point situé à une distance de mille cinq cent soixante-quatorze pieds et quatre dixièmes (1.574.4) de la ligne de division entre les rangs trois et deux dudit canton d'Eardley, sur une ligne parallèle à l'emprise du chemin de fer Canadien Pacifique, ledit point étant à une distance de cinquante pieds (50') de la borne est dudit droit de passage et mesuré dans une direction est; de là, allant dans une direction sud-est et sur une distance de cent vingt^cinq pieds(125') dans une ligne parallèle audit droit de passage et à une distance de cinquante pieds de sa limite est; de là, allant dans une direction nord-est à angles droits sur une distance de trois cent cinquante pieds (350'); de là.allant dans une direction nord-est à angles droits sur une distance de cent vingt-cinq pieds (125'); de là.allant dans une direction sud-est, à angle droit, sur une distance de trois cent cinquante pieds (350') jusqu'au point de départ: le tout étant borné comme suit: Road\", as actually travelled; and said use of right of way including also the use of Caron's Road, jointly with all other interested parties.Taxes scol.Total School taxes .6 $ 72.89 $ 44.66 S 117.55 An immoveable situate in the township of Eardley, in all that property known and designated as being formed of part of lot fifteen (P.15) in the sixth range (6), according to the official plan and book of reference of said township of Ëardley, said emplacement of irregular form being situate at the northeast of a private road leading to the Ottawa River and more particularly described as follows: Commencing at a point situate at the northeast of a private road above mentioned coinciding with the northwesterly corner of the property of Roland Duguay or representatives, as described and bounded in a deed of sale executed before Me Charles Munn, notary, under number 276 of his records, copy whereof registered at the Gatineau Registry Office, at Maniwaki, under number 43-450; thence, in a northwesterly direction zlong the northeasterly side of the said private road, a distance of one hundred and twenty-nine feet (129') to a point; thence, in an easterly direction, a distance of one hundred and one feet (101') to a point located on the western limit of the property of Pierre Tremblay or representatives, thence, in a southerly direction along the westerly limit of the property of Pierre Tremblay or representatives, a distance of one hundred and twenty-six feet (126') to a point located at the northeasterly corner of the property of said Roland Duguay above referred to; thence, in a westerly direction along the northerly limit of the property of said Roland Duguay.a distance of one hundred and thirty-seven feet (137') back to the commencing point.The said emplacement is indicated by a post planted at each corner and is bounded as follows: Towards the west by the private road; towards the north by another part of the same lot, the property of one named Leduc or representatives; towards the east by another part of the same lot, property of Pierre Tremblay or representatives and towards the south by another part of the same lot, the property of Roland Duguay or representatives.With buildings thereon erected, members and appurtenances and right of way.2 14.83 39.90 54.73 A certain piece or parcel of land forming part of lot number three (P.3) in the second range.(R.2), upon the official plan and book of reference of the township of Eardley, unofficially known as being lot number twelve, upon the unofficial subdivision plan of said lot number three (3-12), more particularly described as follows: Commencing at a point situated at a distance of one thousand five hundred and seventy-four feet and four tenths of a foot (1674.4'J from the division line between range three and two of said township of Eardley on a line parallel with the Canadian Pacific Railway, right of way said point being distant fifty feet (50') from the eastern boundary of said right of way and measured in an easterly direction* thence, proceeding in a southeasterly direction, a distance of one hundred and twenty-five feet (125') on a line parallel in the said right of way, and at a distance of fifty feet from its eastern limit; thence, proceeding in a northeasterly direction at right angles a distance of three hundred and fifty feet (350') thence, proceeding in a northeasterly direction at right angles a distance of one hundred and twenty-five feet (126')- thence proceeding in a southeasterly direction, at right angle a distance of three hundred and fifty feet (350') to the point of commencement: the whole being bounded .is follows: To the Corporation municipale du canton d'Eardley \u2014 Canton d'Eardley Municipal Corporation of the township of Eardley \u2014 Township of Eardley Taxes Noms Rang munie.Lots Names Range Munie.taxes QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 779 Au sud-oueat par un terrain de stationnement de cinquante pieds de large (60').au sud-est par une subdivision non officielle numéro treize dudit lot numéro trois (3-13) au nord-est par une rue projetée de soixante-six pieds de large (66') et au nord-ouest par la subdivision non officielle numéro onze dudit lot numéro trois (3-11).southwest, by a parking reserve of fifty feet in width (50*) to the southeast by unofficial subdivision number thirteen of said lot three (3-13) to the northeast by a proposed street of sixty-six feet in width (66') and to the northwest, by unofficial subdivision number eleven of said lot three (3-11).Taxes Taxes Noms Rang munie.scol.Lots Total Names Range Munie.School taaes taxes Campeau, J.-Aurèle.P.19.Un certain emplacement situé dans le canton d'Eardley, comté de Gatineau, province de Québec, plus spécialement décrit comme étant une partie du lot dix-neuf (P.19) dans le septième rang (R.7) .aux plan et livre de renvoi officiels du canton Eardley, de forme rectangulaire, mesurant cinquante pieds (50') dans ses limites nord et sud.sur une profondeur de 112' dans ses limites est et ouest, étant situé à l'ouest d'un chemin privé; l'extrême coin nord-ouest de la propriété présentement décrite est situé à cinquante-cinq pieds (55') mesuré dans une direction ouest du côté est du chemin du Roy, et borné comme suit: au nord, au sud et à l'ouest par le résidu du lot dix-neuf (19) et à l'est par une autre partie du même lot, étant un chemin privé.Avec bâtisses.Côté, Mme-Mrs.Jules.P.14.Un certain emplacement connu et désigné comme étant partie du lot numéro quatorze (P.14), dans le sixième rang, (R.6), canton d'Eardley, mesurant cent pieds (100') de profondeur mesure anglaise plus ou moins et borné comme suit: En front à l'est par un chemin privé; au sud par une autre partie du même lot, la propriété d'un nommé Charest ou représentants; vers le nord et l'ouest par le résidu dudit lot, la propriété du vendeur.Avec bâtisses et droit de passage.Gosselin, Hubert.P.10B.Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot dix (10) dans le septième rang (R.7) du canton d'Eardley, ledit morceau de terre ayant front sur un chemin venant du chemin Public mesurant 262' en front vers le nord, mesure le long dudit chemin privé, 146' à l'ouest, 232' au sud et 160' à l'est Le tout borné comme suit: en front par ledit chemin privé venant dudit chemin public, route #8, à l'ouest et au sud par autres parties dudit lot dix B (P.10B) propriété de Monsieur Edouard Papineau ou représentants, et à l'est par la limite ouest de la propriété de Monsieur Agret Lusk ou représentants.Le coin au nord-est du morceau de terre décrit aux présentes, est situé au point d'intersection entre le chemin public, Route §S, et le coin sud-est dudit chemin privé.Les côtés est et ouest du morceau de terre sont parallèles et chaque coin est marqué par quatre poteaux plantés en terre, le tout bien connu des parties.Avec tous les bâtiments y dessus érigés, circonstances et dépendances.Joanisse, Albert.P.15.Un immeuble ou emplacement situé dans le canton d'Eardley, comté de Gatineau, province de Québec, consistant en toute cette propriété connue et désignée comme étant formée d'une partie du lot quinze (P.15) dans le sixième rang (R.6) aux plan et livre de renvoi officiels du canton d'Eardley, et ledit emplacement de forme irrégulière plus particulièrement décrit et borné comme suit: à l'Est par le chemin Tremblay et mesurant cent un pieds (101') plus ou moins, au sud ou sud-ouest par une autre partie du même lot étant partie de la propriété de Madame Arthur Groulx ou représentants telle que décrite aux termes d'un acte de vente exécuté devant le notaire, le 29 juillet 1959, sous le numéro 12734, et dont copie enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Gatineau, sous le numéro 49836 et mesurant quatre-vingt-quatorze (94') pieds, plus ou moins; et au nord par une .7 S 88.35 S 42.49 S 130.84 A certain emplacement situated in the township of Eardley, county of Gatineau, Province of Québec, more specifically described as being part of lot nmeteen (P.19) in the seventh range (R.7), in the official plan and book of reference for the township of Eardley, of rectangular configuration, measuring fifty feet (50') in its east, north and south, on a depth of 112' in its limits and west limits, being situated to the west of a private road; the extreme northwest corner of the property herein described is situated fifty-five feet (55') measured in a westerly direction to the east side of the King's Highway and bounded as follows: On the north, on the south and on the west by the remaining part of lot nineteen (19) and on the east by another part of the same lot, being a private road.With buildings.6 62.56 90.96 153.52 A certain emplacement known and designated as being part of lot number fourteen (P.14), in the sixth range (R.6), township of Eardley, measuring one hundred feet (100') in depth English measure more or less and bounded as follows: In front on the east by a private road; on the south by another part of the same lot, property of one, Charest, or representatives; on the north and on the west by the remaining part of the said lot, property of the vendor.With buildings and right of way.7 75.12 156.08 231.20 An immovable known and designated as being part of lot ten (10) in the seventh range (R.7) of the township of Eardley, the said piece of land fronting on a road coming from the Public Highway, measuring 262' in front towards the north, measured along the said private road, 146' on the west, 232' on the south and 160' on the east.The whole bounded as follows: in front by the said private road coming from the said public road, Highway *8, on the west and on the south by other parts of said lot ten B (P.10B) property of Mr.Edouard Papineau or representatives, and on the east by the west limit of the property of Mr.Agret Lusk or representatives.The northeast corner of the piece of land described herein, is situated at the point of intersection between the public road.Highway #8, and the southeast corner of the said private road.The east and west sides of the piece of land are parallel with a marking stake at each corner the whole well known to the parties.With all the buildings erected thereon, circumstances and dependencies.6 57.97 79.19 137.16 An immovable or emplacement situated in the township of Eardley, county of Gatineau, Province of Québec, consisting of all of that property known and designated as being made up of part of lot fifteen (P.15) in the sixth range (R.6) in the official plan and book of reference for the township of Eardley, and the said emplacement of irregular configuration more specifically described and bounded as follows: On the east by Tremblay Road and measuring one hundred one feet (101') more or less, on the south or southwest by another part of the same lot being part of the property of Mrs.Arthur Groulx or representatives as described in the terms of a deed of sale executed before the notary, on July 29, 1959, under number 12734, a copy of which was registered at the Gatineau Division Registry Office, under number 49836, and measuring ninety-four (94') feet, more or less; and on the north by another part 780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 autre partie du même lot étant la propriété d'un nommé Aimé Séguin ou représentants et mesurant cinquante-sept pieds (57') plus ou moins.Avec bâtisses dessus érigées, circonstance et dépendances.of the same lot being the property of one.Aimé Séguin, or representatives and measuring fifty-seven feet (57 ) more or less.With buildings erected thereon, circumstances and dependencies.Taxes Taxes Noms Rang munie.scol.Lots Total Names Range Munie.School taxes taxes Legros, Mme-Mrs.Eusèbe.P.14.Un certain emplacement situé a Luskville connu et désigné comme étant partie du lot numéro quatorze (P.14) dans le sixième rang (R.6) aux plan et livre de renvoi officiels du canton d'Eardley, mesurant 52' de largeur par 90' de profondeur, (52x90).mesure anglaise et plus ou moins, et étant borné comme suit- au surf pnr un chemin M.He tous les autres côtés par le résidu dudit lot appartenant à Philias Bélisle ou représentants.Avec bâtisses et droit de passage.Perrier, Joseph A Gédéon.P.19B.Un immeuble situé dans le canton d'Eardley, comté de Gatineau, bureau d'enregistrement de Gatineau, province de Québec, consistant en tout cette propriété connue et désignée comme étant le lot dix-neuf B (19B), dans le huitième rang (R 8), aux plan et livre de renvoi officiels du canton d'Eardley, contenant cent acres (100 a.) en superficie, plus ou moins.Avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.À distraire cette partie dudit lot 19B appartenant à Philippe Perrier ou représentants.Perrier.Joseph.P.19.Un immeuble ou emplacement situé dans le canton d'Eardley, comté de Gatineau.province de Québec, consistant de toute cette propriété connue et désignée comme faisant partie du lot dix-neuf (P.19) dans le septième rang (R.7) aux plan et livre de renvoi officiels du canton d'Eardley, et ledit emplacement de forme rectangulaire situé au nord d'un petit chemin privé plus particulièrement décrit et borné comme suit: Au sud par le chemin privé ci-dessus référé et mesurant soixante pieds (60'); à l'ouest par un autre partie du même lot demeurant la propriété des vendeurs ou représentants, et mesurant cent pieds (100') ; au nord par autre partie du même lot demeurant propriété des vendeurs ou représentants et mesurant soixante pieds (60') et à l'est par autre partie du même lot demeurant la propriété des vendeurs et mesurant cent pieds (100').Avec bâtisses dessus érigées.Perrier, Mme-Mrs.Joseph.P.19.Un immeuble ou emplacement Bitué duns le canton d'Eardley, comté de Gatineau, province de Québec, consistant en toute cette propriété connue et désignée comme étant parties du lot dix-neuf (P.19).dans le septième rang (R.7), aux plans et livre de renvoi officiels du canton d'Eardley, lesquelles parties sont décrites comme suit: \u2022 A) Une partie dudit lot dix-neuf (P.19), du rang sept, canton d'Eardley, est décrite et bornée comme suit: au sud par une autre partie du même lot, demeurant la propriété de l'acquéreur ou représentants, et mesurant cent vingt pieds (120'); à l'ouest par une autre partie du même lot, la propriété du vendeur ou représentants mesurant dix-huit pieds (18'); au nord par une autre partie du même lot, la propriété d'un nommé Legendre ou représentants et mesurant quatre-vingt-neuf pieds (89') et à l'est par une autre partie du même lot, demeurant la propriété du vendeur ou représentants et mesurant soixante-dix-huit pieds (78').B) Une autre partie dudit lot dix-neuf (P.19) du rang sept (R.7), canton d'Eardley, de forme triangulaire est décrite et bornée comme suit: au sud par le chemin privé et mesurant vingt et un pieds (21').Au nord-ouest par une autre partie du même lot, demeurant la propriété du vendeur ou représentants mesurant quatre-vingt-dix pieds (90') et & l'est par une autre, partie du même lot.demeurant la propriété de l'acquéreur ou représentants et mesurant cent pieds (100').Un autre immeu- .6 S 85.59 $ 76.40 S 161.99 A certain emplacement situated in Luskville known and designated as being part of lot number fourteen (P.14) in the sixth range (R.6) in the official plan and book of reference for the township of Eardley, measuring 52' in width by 90' in depth, (52 x 90).English measure and more or less, and being bounded an follows: On the south by a road and on all other sides by the remainder of the said lot belonging to Philias Bélisle or representatives.With buildings and right of way.8 301.31 511.41 812.72 An immovable situated in the township of Eardley, county of Gatineau, Gatineau Registry Office.Province of Québec, consisting of all of that property known and designated as being lot nineteen B (19B).in the eighth range (R.8).in the official plan and book of reference for the township of Eardley, containing one hundred acres (100 a.), more or less.^Vith buildings erected thereon, circumstances and dependencies.Save and to withdraw this part of the said lot 19B belonging to Philippe Perrier or representatives.7 38.46 104.90 143.36 An immovable or emplacement situated in the township of Eardley, county of Gatineau, Province of Québec, consisting of all of that property known and designated as forming part of lot nineteen (P.19) in the seventh range (R.7) in the official plan and book of reference for the township of Eardley.and the said emplacement of rectangular configuration situated to the north of a small private road more specifically described and bounded as follows: on the south by the aforementioned private road and measuring sixty feet (60') ; On the west by another part of the same lot remaining the property of the vendors or representatives, and measuring one hundred feet (100'); on the north by another part of the same lot remaining the property of the vendors or representatives and measuring sixty feet (60') and on the east by another part of the same lot remaining the property of the vendors and measuring one hundred feet (100').With buildings erected thereon.7 19.42 38.78 58.20 An immovable or emplacement situated in the township of Eardley.county of Gatineau.Province of Québec, consisting of all of that property known and designated as being part of lot nineteen (P.19), in the seventh range (R.7), in the official plan and book of reference for the township of Eardley, which parts are described as follows: \"(A) A part of said lot nineteen (P.19), of range seven, township of Eardley, described and bounded aB follows: On the south by another part of the same lot, remaining the property of the purchaser or representatives, and measuring one hundred twenty feet (120') ; on the west by another part of the same lot, the property of the vendor or representatives measuring eighteen feet (18'); on the north by another part of the same lot, the property one.Legendre.or representatives and measuring eighty-nine feet (89') and on the east by another part of the same lot.remaining the property of the vendor or representatives and measuring seventy-eight feet (78').(B) Another part of said lot nineteen (P.19) of range seven (R.7), township of Eardley, of triangular configuration described and bounded as follows: On the south by the private road and measuring twenty-one feet (21').On the northwest by another part of the same lot.remaining the property of the vendor or representatives, measuring ninety feet (90') and on the east by another part of the same lot, remaining the property of the purchaser or representatives and measuring one QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10i, No.U 781 ble ou emplacement situé dans le canton d'Eardley, comté de Gatineau, province de Québec, consistant en toute cette propriété connue et désignée comme faisant partie du lot dix-neuf (P.19) dans le septième rang (R.7); aux plan et livre de renvoi officiels du canton d'Eardley, et ledit emplacement de forme rectangulaire situé au nord d'un petit chemin privé plus particulièrement décrit et borné comme suit: au sud par le chemin privé ci-dessus référé et mesurant soixante pieds (60') ; à l'ouest par autre partie du même Lot demeurant la propriété du vendeur ou représentants, et mesurant cent pieds (100'); au nord par autre partie du même lot demeurant la propriété du vendeur ou représentants, et mesurant soixante pieds (60') et à l'est par une autre partie du même lot, propriété de Joseph Perrier ou représentants, telle que décrite aux termes de l'acte de vente exécuté devant Me Pierre DesRosiers, notaire, le 22 octobre 1962, sous le numéro 16,699 de ses minutes, dont copie enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Gatineau, le 31 octobre 1962, sous le numéro 60,368 et mesurant cent pieds (100').L'emplacement ci-dessus décrit et présentement vendu est indiqué par un poteau planté à chaque coin et le tout tel qu'actuellement occupé.> Rain ville, Peter J.P.1A-3____ 1.Un certain emplacement situé dans le canton d'Eardley formant partie du lot un « A » (P.1A) du premier rang (R.1) aux plan et livre de renvoi du canton d'Eardley, connu comme étant la subdivision trois non officielle du lot 1 « A > (1A-3) sur un plan préparé par Paul E.Pouliot a.o.q., daté du vingt-neuf mai dix-neuf cent soixante-trois (1963) et plus particulièrement décrit comme suit: Commençant à un point situé au long du côté nord-est d'une rue proposée de cinquante pieds (50') de largeur, à une distance de cent cinquante pieds (150') au sud-est de la ligne separative entre les lots 1 « A » et deux (1 « A » et 2), du premier rang (R.1) canton d'Eardley, de là, allant dans une direction nord-est, sur une distance de cent pieds et six dixièmes (100.6') jusqu'à un certain point situé le long du droit de passage du chemin de fer C.P.R.; de là, tournant et allant dans une direction sud-est sur une distance de cent pieds (100') jusqu'à un certain point; de là, tournant et allant dans une direction sud-ouest sur une distance de quatre-vingt-dix-neuf pieds et neuf dixièmes (999') jusqu'à un certain point au long du côté nord-est de la rue proposée; de là, tournant et allant dans une direction nord-ouest sur une distance de cent pieds (100') jusqu'au point de départ; le tout de mesure anglaise, plus ou moins et borné comme suit: Vers le sud-ouest par la rue proposée vers le nord-est par l'emprise du C.P.R.; vers le nord-ouest par une partie du même lot étant la subdivision non officielle deux du lot originaire un « A » (1A-2); et vers le sud-est par une autre partie du même lot étant la subdivision non officielle quatre du lot originaire un « A » (1A-4), propriété de Hubert Drouin ou représentants.2.Un certain emplacement étant une partie non divisée vingt-huit de cette partie du lot deux (P.2) du premier rang (R.1) dudit canton d'Eardley, mesurant quatre-vingt-dix pieds (90') de largeur en façade, sur cent cinquante pieds (150') de profondeur, plus ou moins, et borné comme suit: Vers le nord par un chemin public, vers le sud par la rivière Ottawa, vers l'est par un droit de passage réservé par le vendeur ou représentants; et vers l'ouest par la propriété de Lucien Florent ou représentants.Bertrand, Raymond.P.2.Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro deux (P.2) rang un (R.1) canton d'Eardley, comté de Gatineau, division d'enregistrement de Gatineau, mesurant cinquante (50') en front sur le chemin municipal, cin- Îliante pieds (50') à l'arrière, et cent vingt-cinq pieds (125') b profondeur et borné comme suit: Au nord par une autre hundred feet (100').Another immovable or emplacement situated in the township of Eardley, county of Gatineau, Province of Québec, consisting of all of that property known and designated as forming part of lot nineteen (P.19) in the seventh range (R.7), in the official plan and book of reference for the township of Eardley, and the said emplacement of rectangular configuration situated to the north of a small private road more specifically described and bounded as follows: On the south by the aforementioned private road and measuring sixty feet (60\") ; on the west by another part of the same lot remaining the property of the vendor or representatives, and measuring one hundred feet (100'); on the north by other part of the same lot remaining the property of the vendor or representatives, and measuring sixty feet (60') and on the east by another part of the same lot, property of Joseph Perrier or representatives, as described in the terms of the deed of sale executed before Mr.Pierre Desrosiers, notary, on October 22, 1962, under number 16,699 of his minutes, a copy of which was registered at the Gatineau Registry Division Office, on October 31, 1962, under number 60,368 and measuring one hundred feet (10Q').The emplacement described above and presently being sold is marked by stakes at each corner and the whole such as presently occupied.\" Taxes scol.Total School taxes .1 I 10.21 $ 26.22 $ 36.43 1.A certain emplacement situated in the township of Eardley forming part of lot one \"A\" (P.1A) in the first range (R.1) upon the official plan and book of reference of the township of Eardley, known as unofficial subdivision three of lot one \"A\" (1A-3) on a plan prepared by Paul-E.Pouliot, q.L.s.dated on the twenty-ninth of May, nineteen hundred and sixty-three (1963) and more particularly described as follows: Commencing at a point situated along the northeasterly side of a proposed street of fifty feet (50') in width, at a distance of one hundred and fifty feet (150') to the southeast of the division line between lots one \"A\" and two (1A and 2), range first (R.1) township of Eardley thence, going in a northeasterly direction, a distance of one hundred feet and six tenths of a foot (100.6') to a certain point situated along the C.P.R.right of way; thence, turning and going in a southeasterly direction a distance of one hundred feet (100') to a certain point; thence, turning and going in a southwesterly direction, a distance of ninety-nine feet and nine tenths of a foot (99.9') to a certain point, along the northeasterly side of the proposed street; thence, turning and going in a northwesterly direction, a distance of one hundred feet (100') to the point of commencement; the whole English measure, more or less and bounded as follows: Towards the southwest by the proposed street; towards the northeast by the C.P.R.right of way; towards the northwest by part of same lot, being unofficial subdivision two of original lot one \"A\" (1A-2); and towards the southeast by another part of the same lot, being unofficial subdivision four of original lot one \"A\" (1A-4), the property of Hubert Drouin or representatives.2.A certain emplacement being one undivided twenty-eight of that part of lot two (P.2) in the first range (R.1) said township of Eardley, measuring ninety feet (90') in width, in front, by one hundred and fifty feet (150') in depth, more or less, and bounded as follows: Towards the north by a public road; towards the south by the Ottawa River; towards the east by a right of way reserved by the vendor or representatives; and towards the west by the property of Lucien Florent or representatives.1 4.46 24.56 29.02 An immovable known and designated as being part of lot number two (P.2) range 1 (R 1), township of Eardley, county of Gatineau, Gatineau Registration Division, measuring fifty (60') in front along the municipal road, fifty feet (50') in the rear, and one hundred twenty-five feet (125') in depth and bounded as follows: On the north by another part of said lot Taxes Noms Rang munie.Lots Names Range Munie.taxes 782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101' année, n° 4 partie dudit lot numéro 2, rang 1, la propriété du vendeur ou ou représentants; au sud par le chemin municipal; à l'est par autre partie dudit lot numéro 2, la propriété de Georges Bour-geau ou représentants; à l'ouest par autre partie dudit lot, la propriété de Michel Riopel ou représentants.Sujet à un droit de passage commun.number 2, range 1, the property of the vendor or representatives; on the south by the municipal road; on the east by another part of said lot number 2, the property of Georges Bourgeau or representatives; on the west by other part of said lot, the property of Michel Riopel or representatives.Subject to a common right of way.Taxes Taxes Noms Rang munie.scol.LoU Total Names Range Munie.School taxes taxes Allen, Léo.P.18.Le lot dix-huit dans le septième rang du canton d'Eardley excepté les parties de tel lot vendues par actes enregistrées et avec bâtisses dessus érigées.Boucher, Fernand.P.18.Un terrain connu et désigné comme étant partie du dix-huit (P.18), rang 7, aux plan et livre de renvoi officiels du canton Eardley, mesurant soixante-quinze pieds (75') le long de la rivière Ottawa et dans sa limite nord par toute la profondeur qu'il y a de la ligne des plus hautes eaux de ladite rivière Ottawa à un chemin privé situé au nord du morceau de terrain par les présentes décrit, le tout borné comme suit: Au sud par la rivière Ottawa, à la ligne des plus hautes eaux; à l'ouest par autre partie du même lot, propriété de J.R.Robitaille ou représentants; au nord par une autre partie du même lot servant de chemin privé; à l'est par autre partie du même lot propriété du vendeur ou représentants.Avec droit de passage e£ bâtisses dessus érigées.Dupont, René.P.19.Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot 19 rang 7 aux plan et livre de renvoi officiels pour le canton d'Eardley, plus particulièrement décrit comme suit: Commençant à un point étant à cent pieds (100') au nord du rivage de la Rivière Ottawa à la marque des hautes eaux naturelles et à trois cent cinquante pieds (350') à l'ouest de la ligne de division entre les lots 19 & 18 dudit rang 7, de ce point, dans une direction ouest sur une distance de cinquante pieds (50') jusqu'à un point, de ce point dans une direction sud parallèlement à ladite ligne de division entre lesdits lots 19 & 18 et à quatre cents pieds (400') à l'ouest d'icelle, sur une distance de 199' jusqu'au bord de la rivière Ottawa à la marque des hautes eaux naturelles, de ce point longeant la rive de ladite rivière Ottawa à la marque des hautes eaux naturelles, vers l'est, sur une distance de cinquante pieds (50') jusqu'à un point, de ce point, vers le nord parallèlement à la ligne de division entre lesdits lots dix-neuf et dix-huit et à trois cent cinquante pieds (350') à l'ouest d'icelle sur une distance de (100') cent pieds jusqu'au point de départ, le tout mesures anglaises et plus ou moins, ledit immeuble borné en front, au sud ou sud-ouest par la rivière Ottawa à la marque des hautes eaux naturelles, en arrière au nord par une autre partie du même lot, la propriété de M.Alexandre Desjardins ou représentants, d'un côté à l'ouest paruneautre partie du même lot, propriété dudit Alexandre Desjardins ou représentants, de l'autre côté, à l'est par une autre partie du même lot, la propriété de Monsieur Armand Monfils, ou représentants, tel que plus au long décrite dans un acte d'acquisition reçu devant Pierre DesRosiers, notaire, sous le numéro 7742 de ses minutes, enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Gatineau sous le numéro 36,497 avec toutes les bâtisses y érigées et droit de passage.Lamothe, Jean-Paul.P.19.Un immeuble sis dans le canton d'Eardley, comté de Gatineau, province de Québec, consistant en toute cette propriété connue et désignée comme étant formée d'une partie du ,ot dix-neuf (P.19) dans le septième rang, dudit canton d'Eard ley, aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton et ledit emplacement plus particulièrement décrit et borné comme suit: au nord ou nord-est par un chemin privé et mesurant soixante-treize pieds (73') ; à l'est ou sud-est par un chemin .7 S 53.35 8 64.10 $ 117.45 Lot eighteen in the seventh range of the township of Eardley except the part of such lot sold by registered deeds and with buildings erected thereon.7 95.18 95.18 A lot of land known and designated as being part of number eighteen (P.18), range 7, in the official plan and book of reference for the township of Eardley, measuring seventy-five feet (75') along the Ottawa River and in its north limit by the full distance between the high-water mark of the said Ottawa River to a private road situated to the north of a piece of land hereby described, the whole bounded as follows: on the south by the Ottawa River, at its high-water mark; on the west by other part of the same lot, property of J.-R.Robitaille or representatives; on the north by another part of the same lot serving as a private road; on the east by other part of the same lot property of the vendor or representatives.With right of way and buildings erected thereon.7 41.07 83.12 124.19 An immovable known and designated as being part of lot 19 range 7 in the official plan and bobk of reference for the township of Eardley, more fully described as follows: Beginning at a point being one hundred feet (100') north of the bank of the Ottawa River at the natural high-water mark and three hundred fifty feet (350') west of the dividing line between lots 19 and 18 of said range 7, from this point, in a westerly direction over a distance of fifty feet (50') up to a point, from this point in a southerly direction parallel to the said dividing line between said lots 19 and 18 and four hundred feet (400') west of the latter line, over a distance of 199' up to the bank of the Ottawa River at the natural high-water mark, from this point along the shore of the said Ottawa River at the natural high-water mark, towards the east, over a distance of fifty feet (50') up to a.point, from this point, towards the north parallel to the dividing line between said lots nineteen and eighteen and three hundred fifty feet (350') west of the latter line over a distance of (100') one hundred feet up to the starting point, the whole English measure and more or less, the said immovable bounded in front, on the south or southwest by the Ottawa River at the natural high-water mark, in the rear on the north by another part of the same lot, the property of Mr.Alexander Desjardins or representatives, on one side, to the west by another part of the same lot, property of the said Alexander Desjardins or representatives, on the other isde, to the east by another part of the same lot, the property of Mr.Armand Monfils, or representatives, as more fully described in a deed of purchase executed before Pierre DesRosiers, notary, under number 7742 of his minutes, registered in the Gatineau Division Registry Office under number 35,497, with all the buildings erected thereon and right of way.4.46 31.35 oi.oo 35.81 An immovable situated in the township of Eeardley, countv Gatineau, Provmçe of Québec, consisting of all of that property known and designated as being made up of part of lot nine een (P.19) m the seventh range, of the said township of Eardley, in the official plan and book of reference for the said township and the said emplacement more specifically described and bounded as follows: On the north or northeast by a private road and measuring seventy-three feet (73'); on the coot or Of QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 783 privé et mesurant cent huit pieds (108') ; au sud ou sud-ouest par une autre partie du même lot, demeurant la propriété du vendeur ou représentants et mesurant quarante et un pieds (41'); à l'ouest ou nord-ouest par une autre partie du même lot, demeurant la propriété du vendeur ou représentants et mesurant quatre-vingt aix-sept pieds (97').Avec droit de passage.southeast by a private road and measuring one hundred eight feet (108'); on the south or southwest by another part of the same lot, remaining the property of the vendor or representatives and measuring forty-one feet (41'); on the west or northwest by another part of the same lot, remaining the property of the vendor or representatives and measuring ninety-seven feet (97').With right of way.Taxes Taxes Noms Rang munie.scol.Lots Total Names Range Munie.School taxes taxes Malette, Jacques.P.15.Un immeuble situé dans le canton d'Eardley, comté de Gatineau, province de Québec, consistant en toute cette propriété connue et désignée comme faisant partie du lot quinze (P.15) dans le sixième rang (R.6), aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton d'Eardley; et ledit emplacement mesurant soixante pieds (60') de largeur (ledit soixante pieds (ÔO7) mesuré en droite ligne le long de la rue Champagne) sur une profondeur de quatre-vingt-pieds (80') mesures anglaises et plus ou moins, et le tout borné comme suit: A l'ouest par la rue Champagne, à l'est par la propriété de Monsieur Alexandre Bélisle ou représentants; au nord par autre partie du même lot étant la subdivision non-officielle 15-4.la propriété de Douaire ou représentants; au sud par une autre partie du même lot, étant la subdivision non-officielle 15-12 propriété de Monsieur Plamondon ou représentants.Avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.Rodrigue, William.P.21.Une propriété située à Black Bay, connue et désignée comme étant partie du lot' numéro vingt et un (P.21) rang huit, d'après les plan et livre de renvoi officiels du canton d'Eardley, comté de Gatineau, mesurant approximativement quatre-vingt-dix-sept pieds (97') de largeur par cent pieds (100') de profondeur, le tout plus ou moins, computées de la ligne des eaux hautes et incluant l'espace entre les lignes des eaux basses et des eaux hautes, bornée comme suit: au sud par la rivière Ottawa, au nord par un chemin, à l'ouest par la propriété de Jules Laverdure ou représentants et à l'est parla propriété de M.Demers ou représentants, le tout tel que présentement occupé, avec droit de passage de la propriété ci-vendues ou décrite au chemin public et avec les bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.Ward, James R.P.2.Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro deux (P.2) dans le premier rang, canton d'Eardley, comté de Gatineau, ledit immeuble mesurant cinquante pieds (50') en front sur le chemin municipal, cinquante pieds (50') à l'arrière par cent vingt-cinq pieds (125') de profondeur, plus ou moins, mesures anglaises et borné comme suit: Au nord par autre partie dudit lot 2, rang 1.la propriété du vendeur; au sud par ledit chemin municipal; à l'ouest par autre partie dudit lot 2, rang 1, la propriété de Dame Fournier ou représentants, et à l'est par une autre partie dudit lot 2, rang 1, la propriété de Raymond Bertrand ou représentants.Avec droit de passage et bâtisses dessus érigées.6 S 1.44 S 126.35 $ 127.79 An immovable situated in the township of Eardley, county of Gatineau, Province of Québec, consisting of nil of that property known and designated as forming part of lot fifteen (P.15) in the sixth range (R.6), in the official plan and book of reference for the said township of Eardley; and the said emplacement measuring sixty feet (60') in width (the said sixty feet (60') measured in a straight line along Champagne Street) by a depth of eighty feet (80') English measure and more or less, and the whole bounded as follows: On the west by Champagne Street, on the east by the property of Mr.Alexandre Bélisle or representatives; on the north by another part of the same lot being unofficial subdivision 15-4, the property of Douaire or representatives; on the south by another part of the same lot, being unofficial subdivision 15-12 property of Mr.Plamondon or representatives.With buildings erected thereon, circumstances and dependencies.8 4.56 243.41 247.97 A property situated at Black Bay, known and designated as being part of lot number twenty-one (P.21) range eight, according to the official plan and book of reference for the township of Eardley, county of Gatineau, measuring approximately ninety-seven feet (97') in width by one hundred feet (100') in depth, the whole more or less, calculated from the high-water mark and including the space between the low-and high-water marks, bounded as follows: On the south by the Ottawa River, on the north by a road, on the west by the property of Jules Laverdure or representatives and on the east by the property of Mr.Demers or representatives, the whole as presently occupied, with right of way from the property herein sold or described to the public road and with the buildings erected thereon, circumstances and dependencies.1 35.78 11.32 47.10 An immovable known and designated as being part of lot number two (P.2) in the first range, township of Eardley, county of Gatineau, the said immovable measuring fifty feet (50') in front on the municipal road, fifty feet (50') in the rear by one hundred twenty-five feet (125') in depth, more or less, English measure and bounded as follows: On the north by another part of said lot 2, range 1, the property of the vendor; on the south by the Baid municipal road; on the west by another part of said lot 2, range 1, the property of Dame Fournier or representatives, and on the east by another part of said lot 2, range 1, the property of Raymond Bertrand or representatives.With right of way and buildings erected thereon.La corporation du village de Des Chênes \u2014 Canton de Hull The Corporation of the village of Des Chênes \u2014 Township of Hull Albert, Mme-Mrs.Raymond.16C250.1 S 199.06 $ 266.26 $ 456.31 Bâtisse seulement sise sur lot.Building only situated on lot.Albert, Raymond.'.16C251.1 88.53 25.61 114.04 Cayer.Marcel.15A 10.1 229.04 214.84 443.88 Aveo bâtisses.With buildings. 784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101' année, n° L Noms Names\tRang Lots Range\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tTotal Avec b&tisse.\t.N.de-of 82 et a.de-of 83.1 With building.\t8 281.13\t8 327.86\t8 608.98 \t\t201.60\t247.17\t448.77 Avec bâtisse.\tWith building.\t\t\t Côté, Gilles.\t.16C318-16B178.1\t241.88\t137.43\t379.31 Avec bâtisse.\tWith building.\t\t\t \t\t249.42\t\t249.42 Avec bâtisse.\tWith building.\t\t\t \t\t215.90\t229.00\t444.90 Avec bâtisse.\tWith building.\t\t\t \t.16B239.1\t203.35\t192.74\t396.09 Avec bâtisse.\tWith building.\t\t\t \t.15A13.1\t393.69\t163.70\t657.39 Avec bâtisse.\tWith building.\t\t\t Latulippe, Arthur.Avec bâtisse.\t.16C p.s.de-of 286 et-and 1 16C287.With building.\t839.44\t283.43\t1,122.87 \t\t287.93\t56.54\t344.47 Avec bâtisse.\tWith building.\t\t\t \t.16C H n.de-of 255.1\t159.47\t109.79\t269.26 Avec bâtisse.\tWith building.\t\t\t \t.15A333.1\t\t3.20\t3.20 Avec bâtisse.\tWith building.\t\t\t Martel, Gilles.\t.16A48.1\t435.25\t\t435.25 Avec bâtisse.\tWith building.\t\t\t Avec bâtisse.\t.lèC H e.de-of 223, 1 16C Y, e.de-of 224.With building.\t592.91\t218.79\t811.70 \t\t244.80\t151.76\t396.66 Et bâtisse.\tAnd building.\t\t\t \t.15A114.1\t370.57\t19.73\t390.30 Et bâtisse.\tAnd building.\t\t\t Et bâtisse.\t.16D Y o.-w.de-of 195____ 1 And building.\t388.09\t137.34\t525.43 \t.16B148.1\t463.01\t291.91\t754.92 Avec bâtisse.\tWith building.\t\t\t Avec bâtisse.\t.S.de-of 79 et n.de-of 78.With building.\t187.85\t214.18\t402.03 Corporation municipale du canton de Cameron \u2014 Canton Cameron Municipal Corporation of the township of Cameron \u2014 Township of Cameron Richard, Augustin, occupé par Richard Aza, 9 pour titres seulement-occupied by Richard Aza for deeds only.4 S 5.60 S 19.88 S 25.48 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol 104, No.4 785 Corporation municipale du canton de Wright \u2014 Canton de Wright Municipal Corporation of the township of Wright \u2014 Wright township Taxes Taxes Noms Rang munie.scol.Lota Total Names Range Munie.School taxes taxes Langlois, Mme-Mrs.Karen.P.2.Partie du lot deux (2) rang sept (7) canton de Wright mesurant soixante sept pieds de large et cent dix-huit de profond borné comme suit: vers le sud par le grand chemin; vers le nord et vers l'est par partie du même lot propriété de Monsieur Prévin Gauthier ou représentants; vers l'ouest par partie du même lot propriété de Donald Pétrin ou représentant avec bâtiments y érigés; moins la partie vendue à Sa Majesté la Reine Elizabeth TI; aux droits de la province de Québec, enregistré le 3 mars 1969 sous le numéro 85237.Fex, Mme-Mrs.John.P.3.Une partie du lot trois (3) rang « D » canton de Wright, connue et désignée comme étant la subdivision non officielle seize et dix-sept dudit lot trois.Bornes et dimensions comme suit: A l'ouest par le lac Pine Valley 155 pieds: au nord par subdivision non officielle 18, mesurant 190 pieds; à l'est par le chemin 148'8\"; au sud par la subdivision non officielle 15, mesurant 200 pieds.Fournier, Pauline.P.1.Une partie du lot un (1) rang « D » canton de Wright, aussi connue et désignée comme étant la subdivision non officielle trente-cinq.Bornes et dimensions comme suit: Au sud-ouest par le lac Pine Valley mesurant 74 pieds; au nord-ouest par la subdivision non officielle 36, mesurant 200 pieds; au nord-est par une partie du lot un et mesurant 142'8\"; et au sud-est par une autre partie du lot un, mesurant 198 pieds.7 $ 5.68 $ 44.51 3 50.19 Part of lot two (2) range seven (7) township of Wright measuring sixty-seven feet wide and one hundred and eighteen deep; bounded as follows: towards the south by the highway, towards the north and towards the east by part of same lot, property of Mr.Prévin Gauthier or representatives towards the west by part of same lot, property of Donald Pétrin or representatives with the buildings erected thereon.To withdraw the part sold to Her Majesty the Queen Elizabeth TI.by the rights of the Province of Québec, registered on March 3, 1969.under number 85237.D 11.06 17.21 28.27 Part of lot three (3) range \"D\", township of Wright, known and designated as being non official subdivision numbers sixteen and seventeen of said lot three.Boundaries and measurements namely: To the west by Pine Valley Lake 155 feet; to the north by subdivision non-official 18 measuring 190 feet; to the east by the road 148'8\"; to the south by subdivision non-official 15 measuring 200 feet.D 5.46 7.45 12.91 Part lot one (1) range \"D\", township of Wright, also known and designated as being non official subdivision thirty-five.Boundaries and measurements namely: To the southwest by Pine Valley Lake measuring 74 feet; to the northwest by non-official subdivision 36 measuring 200 feet; to the northeast by part of lot one and measuring 142'8\"; and to the southeast by another part of lot one measuring 198 feet.Corporation municipale du canton d'Aylwin \u2014 Canton d'Aylwin Municipal Corporation of the township of Aylwin \u2014 Township of Aylwin Gauthier, Marcel.P.21.6 $ 13.22 S 24.33 $ 37.55 Avec bâtisse.With building.Peck, Raymond.30.7 58.46 263.77 322.23 Avec bâtisse dessus érigée, à distraire la portion appartenant With buildings thereon erected, less the portion belonging à Osborne Day ou représentants.to Osborne Day or representatives.Pritchard, Mabel I.(relativement au titre seule- P.22-12, P.22-11.6 101.07 335.31 436.38 ment)-(for title only).Un immeuble connu et décrit comme étant une partie des An immoveable known and described as being parts of lot 12 lots 12 et 11 de la subdivision officielle dU lot originaire numéro and 11 of the official subdivision of the original lot number vingt-deux (P.22-12 & 22-11) et une partie du lot numéro twenty-two (Pis 22-12 and 22-11) and a part of the undivided vingt-deux non divisé, (P.22) tous deux rang six (6) du canton lot number twenty-two (P.22) all in range six (R.6) of the d'Aylwin au cadastre officiel dudit canton, mesurant quatre- township of Aylwin, at the official cadastre of said township, vingts pieds de largeur sur deux cent quatre-vingt huit pieds measuring eighty feet in width by two hundred and eighty- et six dixièmes (288'6\") de profondeur, mesure anglaise et eight feet and six tenths (288.6') in depth English measure plus ou moins, et borné comme suit: au nord-est par des par- more or less, and bounded as follows: Northeasterly by parts of ties des mêmes lots 22-12, 22-11, propriété de Alexander Evan the same lots 22-12, 22-11, property of Alexander Evan Pritchard ou représentants, au sud-est par une partie du lot Pritchard or representatives, southeasterly by part of lot vingt-deux onze (P.22-11) propriété de Keith Ronald Fisher twenty-two, eleven (P.22-11) property of Keith Ronald Carter ou représentants, et partiellement par la propriété Fisher Carter or representatives and part by the property appartenant antérieurement à James Wilson ou représentants, formerly owned by James Wilson or representatives, south- au sud-ouest par une partie du lot vingt-deux (P.22) appar- westerly by part of lot twenty-two (P.22) formerly owned tenant antérieurement à Osborne Day et au nord-ouest par by Osborne Day and northwesterly by lot twenty-two, twelve, le lot vingt-deux, douze, propriété d'Alexander Evan Pritchard property of Alexander Evan Pritchard with all the buildings avec toutes les bâtisses dessus érigées.thereon erected.Succ.-est.Norman Mckenzie.P.48 .6 103.54 103.54 Un immeuble situé dans le cantfon d'Aylwin, comté de Gati- An immoveable situated in the township of Aylwin, county neau, province de Québec, comprenant toute cette propriété of Gatineau, Province of Québec, consisting in all that property connue et désignée comme étant formée d'une partie du lot known and designated as being formed of part of lot number 786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 quarante-,huit (P.48), du sixième rang, conformément aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton d'Aylwin, ledit emplacement plus particulièrement décrit et borné comme suit: Vers l'est par la rivière Gatineau et mesurant cinquante pieds (50') ; vers le sud partiellement par la propriété d'Arthur J.C.Loux ou représentants, ainsi que décrite dans un acte de vente exécuté devant M.Pierre DesRosiers, notaire, le vingt-quatrième jour d'avril dix-neuf cent cinquante-sept, sous le numéro 10393 de ses dossiers, dont une copie est enregistrée au bureau d'enregistrement de Gatineau, sous le numéro 42005.et partiellement par la propriété du vendeur ou représentants et mesurant deux cents pieds (200'ï; vers l'ouest par une autre partie du même lot, propriété du vendeur et mesurant cinquante pieds (50'); vers le nord par une autre partie du même lot, propriété du vendeur ou représentants, et mesurant deux cents pieds (200') l'emplacement ci-dessus décrit et présentement vendu est indiqué par un poteau fixé à chaque coin et bien connu des parties intéressées.Cette vente comprend un droit de passage en faveur de l'acheteur et de ses ayants droit, de manière à communiquer de l'emplacement ci-dessus décrit et présentement vendu au chemin public, uue servitude étant établie à cette fin à rencontre du résidu dudit lot quarante-huit à la faveur du précédent.forty-eight (P.48), sixth range, according to the official plan and book of reference of said township of Aylwin, said emplacement more particularly described and bounded as follows: Towards the east by the Gatineau River and measuring fifty feet (50'); towards the south, partly by the property of Arthur J.C.Loux or representatives, as described in a deed of sale executed before M.Pierre DesRosiers, notary, on the twenty-fourth day of April, nineteen hundred and fifty-seven, under number 10393 of his records, copy whereof registered at the Registry Office of Gatineau, under number 42005, and partly by the property of the vendor or representatives and measuring two hundred feet (200'); towards the west by another part of the same lot, the property of the vendor and measuring fifty feet (50') ; towards the north by another part of the same lot.the property of the vendor or representatives and measuring two hundred feet (200').The emplacement above described and presently sold indicated by a post planted at each corner and well known by the parties hereto.This sale includes in favor of the purchaser and his assigns a right-of-way, for communicate from the emplacement above described and presently sold to the public road, servitude being established to that purpose against the residue of said lot forty-eight in favor of the above Noms Names Lots Rang Range Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total Bâtisse seulement.\t.P.49.6 Building only.\t8 19.38\t* 19.38 \tCorporation municipale du canton de Hull, partie ouest \u2014 Municipal Corporation of the township of Hull, west part \u2014\tCanton de Hull Township of Hull\t Succ.-est.Ambrose Coogan & Theresa Coogan.P.6B, P.6C.Une certaine pièce ou parcelle de terrain, ayant façade su-la route Gatineau (No 11) étant des parties des lots six ¦ C > et G « B * (P.6C et 6B) du septième rang, aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Hull et mesurant cent vingt-cinq pieds (126') au long du chemin principal, en façade et en arrière sur cent vingt-cinq pieds (125') de profondeur, dans ses lignes est et ouest, et bornée comme suit: Au sud, par des parties des mêmes lots appartenant à Robert Gagnon ou représentants; au sud et à l'ouest, pra des parties des mêmes lots appartenant au vendeur.La borne sud délimitée par un cours d'eau; le tout de mesure anglaise et plus ou moins.Mountain Lodge Co.Ltd.P.18A, P.18B Toute cette certaine parcelle de terrain et lieux situés dans le canton de Hull, dans le comté Gatineau, en la province de Québec, et étant composée d'une partie du lot 18-a et 18-b, rang 8, dudit canton de Hull conformément aux plan et livre de renvoi officiels, ladite parcelle de terrain peut être plus particulièrement décrite comme suit: Commençant à un point sur la ligne separative entre les lots dix-huit « A » et dix-huit « B » (18a et 18b) dudit huitième rang, ledit point est distant de quinze pieds (15') en direction ouest de l'intersection de ladite ligne separative avec la ligne separative entre lesdits lots et le lot dix-sept (17) du même rang; de là au sud un degré, 23 minutes à l'est (S.1° 23') une distance de cent cinquante-neuf pieds et demi (159.6') ; de là, au sud quatre-vingt-huit degrés à l'ouest (S.88° O.) une distance de quatre cent cinquante pieds (460') ; de là, au nord 1 degré, vingt-trois minutes ouest (N.1° 23' O.), une distance cent cinquante-neuf pieds et demi (159.5') ; de là, au nord quatre-vingt-huit degrés est (N.88° E.) une distance de quatre cent cinquante pieds (450') jusqu'au point de départ.Ladite parcelle de terrain présentement décrite étant bornée au nord par une partie du lot 18-A, propriété d'un certain Paul Horsdal ou représentants, à l'est par un chemin d'accommodation, au sud et à l'ouest par le résidu dudit lot 18-B, propriété de Harry Dunne ou de ses 32.17 .7 8 5.60 8 26.67 8 A certain piece or parcel of land, fronting on the Gatineau Highway (route No.11), being parts of lots six \"C\", six \"B\" (Pts.6C and 6B), in the seventh range, upon the official plan and book of reference of the township of Hull, measuring one hundred and twenty-five feet (125') along the highway, in front, and in rear, by one hundred and twenty-five feet (125') in depth, in the easterly and westerly lines; and bounded as follows: To the south by parts of the same lots, belonging to Robert Gagnon or representatives; to the south and west by parts of the same lots, belonging to the vendor; the southern boundary being delimited by a watercourse; the whole English measures and more or less.8 175.65 968.35 1,144.00 All that certain parcel of land and premises situated in the township of Hull, in the county of Gatineau, in the Province of Québec, and being composed of part of lot 18-a and 18-b.range 8, in the said township of Hull according to the official plan and book of reference, which said parcel may be particularly described as follows: Commencing at a point on the division line between lots eighteen-A and eighteen-B (18A and 18B) in the said eight range which point is distant fifteen feet (15') in westerly direction from the intersection of the said division Une with the division line between the said lots and lots seventeen (17) in the same range; thence, south one degree, 23 minutes east (S 1° 23') a distance of one hundred and fifty- SS3 ?£ ss?w , a*- , 0 ;Ahencf \u2022 ao,uth eighty-eight degrees west (S.88 W.) a distance of four hundred and fifty feet (450'), SWfft nor,t.h one de,Kree, twenty-three minutes west.(N.1° wnwrnA™ one hundred and fifty-nine and a half feet (159.5), thence north eighty-eight degrees east (N.88\" of commencement.The said parcel of land presently described being bounded to the north by part of lot 18A the properly of one Paul Horsdal or representatives, to the east by a forced road and to the south and west by the residue of the said lot 18-B the property of Harry Dunne of his assigns, and contai: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10i, No.I 787 ayants droit et contenant en superficie un acre et sept dixièmes, plus ou moins; de là, au sud 88° ouest le long de la ligne de clôture formant la borne sud dudit lot 18-A une distance de 522.3 pieds; de là, N.1° 23' O., une distance de cent vingt-trois pieds jusqu'au centre du chemin; de là, suivant la ligne centrale dudit chemin pour lesdites portées et distances: N.88° E.90 pieds.N.85° 42' E.100.1 pieds.N.80° 01' E.101 pieds.N.68° 42' E.105.9 pieds, S.60° 39' E.133.2 pieds jusqu'à l'intersection avec un chemin conduisant au nord; de là, suivant la ligne centrale dudit chemin N.00° 65' O.287.8 pieds et N.8° 16' E.112 pieds; de là, parallèlement à la borne sud du lot 18-A du rang 8 N.88° est 465 pieds, plus ou moins, jusqu'à la ligne de clôture sur la borne est dudit lot 18-A en une direction générale du S.1.23' E.489.3 pieds, plus ou moins jusqu'à la borne sud dudit lot 18-A ; dé là, S.1 23' E.au long de la borne ouest d'un chemin d'accommodation 169.6 pieds, plus ou moins jusqu'au point de départ.Ladite parcelle de terrain peut être plus amplement décrite comme étant bornée vers le nord par la partie restante du lot 18-A rang 8, propriété de Paul Horsdal ou représentants, vers l'est par le lot 17-A.et un chemin d'accommodation vers le sud par la partie restante du lot 18-B rang 8, et vers l'ouest, par la partie restante du lot 18-A et 18-B rang 8.Ladite parcelle contient en dimension 8 acres et .5 d'acre, mesure anglaise et plus ou moins.À distraire cette partie vendue selon l'acte 61176, enregistré le 1er mars 1963, le résidu contenant environ 6 acres et H, avec les bâtisses dessus érigées.Description de la partie vendue selon l'acte No 61176: Une partie du lot dix-huit « A > (18A) du huitième rang du canton de Hull Ouest, comté de Gatineau, province de Québec.Commençant à un point de la ligne separative entre les lots 18-A et 18-B du huitième rang sur le bord ouest du droit de passage S.88° O.le long de cette ligne separative, une distance de 532.4 pieds; de là, N.10° 23' O.une distance de 123 pieds jusqu'au centre d'un chemin; de là, suivant la ligne centrale dudit chemin pour les portées et distances suivantes: N.88° E.90 pieds, N.85° 42' E.100.1 pieds N.80° 0.1 E.101 pieds N.68° 42' E.105.9 pieds.S.50° 39' E.133.2 pieds jusqu'à l'intersection avec un chemin de droit de passage conduisant au nord; de là, suivant le bord ouest du droit de passage jusqu'au point de départ, bornée comme suit : au nord, au nord-ouest, à l'ouest et à l'est par partie dudit lot 18-A, et au sud par partie dudit lot 18-B.Taylor, Ronald E.P.13.Une certaine pièce ou parcelle de terrain, de forme triangulaire située à « Kird's Ferry » dans le canton de Hull, connue et désignée comme faisant partie du lot numéro treize (P.13) du dixième rang aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Hull, et mesurant cent trente-huit pieds (138') à la base et cent cinquante pieds sur sa ligne nord, cent quatre-vingts pieds (180') sur sa ligne sud-est et étant bornée comme suit: à l'ouest par un chemin privé; au nord par une autre portion du même lot, indiquée comme étant l'emplacement numéro deux (2) rapporté dans l'acte; et au sud-est par un autre chemin correspondant avec le premier ci-dessus mentionné.Avec le droit de passage en commun avec tous les autres y ayant droit, sur les chemin ou droits de passage bordant ladite propriété à l'ouest et sud-est, de manière à communiquer avec le chemin public.Trudel, Mme-Mrs.Henri.P.21C.Un immeuble situé dans le canton de Hull, comté de Gatineau, province de Québec, comprenant toute cette propriété connue et désignée comme faisant partie du lot vingt et un \u2022 C » (P.21C) du quinzième rang (R.15) conformément aux plan et livre de référence dudit canton de Hull, et étant la partie nord-ouest de la propriété cédée à Archibald Daugherty, ning in area one and seven tenths acres more or less: Thence S.88° W.along the fence line forming the southerly boundary of said lot 18-A a distance of 622.3 feet; thence, N.1° 23' W., a distance of 123 feet to the center of a roadway; thence, following the center line of said roadway for the following bearings and distances: N.88° E.90 feet, N.85° 42' E.100.1 feet, N.80° 01' E.101 feet, N.68° 42' E.105.9 feet, S.50° 39' E.133.2 feet to the intersection with a roadway leading north; thence, following the center line of said roadway N.00° 55' W.287.8 feet, and N.8° 16' E.112 feet; thence, parallel to the southerly boundary of lot 18-A in range 8, N.88° E.466 feet, more or less, to the fence line on the easterly boundary of said lot 18-A in a general direction of S.1° 23' E.489.3 feet, more or less to the southerly boundary of said lot 18-A; thence, S.1° 23' E.along the westerly boundary of a forced road 159.5 feet, more or less, to the place of commencement.The said parcel may be further described as being bounded towards the north by the remaining part of lot 18-A, range 8, the property of Paul Horsdal or representatives, towards the east, by lot 17-A, and a forced road towards the south by the remaining part of lot 18-B.ranee 8.and towards the west, by the remaining part of lot 18-A and 18-B range 8.The said parcel contains by measurement 8.5 acres, English measure, be the same more or less; Less that part sold by deed 61176, registered March 1, 1963, the residue containing about 63^ acres, with the buildings thereon erected.Description of the part sold by deed No.61176: Part of lot eighteen \"A\" (18A) of the eight range of the township of West Hull, county of Gatineau, Province of Québec.Commencing at a point of the division line between lots 18A and 18B, in the eight range on the western edge of the right of way S.88° W.along this division line a distance of 532.3 feet, thence, N.10° 23' W.a distance of 123 feet to the centre of a roadway ; thence, following the centre line of said roadway for the following bearings and distance: N.88° E.90 feet, N.85° 42' E.100.1 feet.N.80° 01' E.101 feet N.68° 42' E.105.9 feet S.50° 39' E.133.2 feet, to the intersection with a roadway right of way leading north thence, following the western edge of the right of way to the place of commencement, bounded as follows: to the north, to the northwest, to the west and to the east, by part of said lot 18-A ,and to the south, by part of said lot 18-B.Taxes scol.Total School taxes .10 $ 99.90 S 99.90 A certain piece or parcel of land, of triangular figure, situate at Kird'sFerry, in the township of Hull, known and designated as being part of lot number thirteen (P.13) in the tenth range, upon the official plan and book of reference of the township of Hull, measuring one hundred and thirty-eight feet (138') on the base and one hundred and fifty feet (160') in its north line, and one hundred and eighty feet (180') in its southeastern line and being bounded as follows: Westerly by a private roadway; northerly by another portion of same lot, indicated as emplacement number two (2) on the plan referred on the deed; and southeasterly by another roadway connecting with the one first above men-tionned.With the right of passage in common with all others having rights therein, on the roadways or eights-of-way bounding said property on the west and southeast, in order to communicate with the public road.16 $ 31.85 51.85 83.70 An immoveable situate in the township of Hull, county of Gatineau, Province of Québec, consisting in all that property known and designated as being part of lot twenty-one \"C\" (P.21C) in the fifteenth range (R.XV) according to the official plan and book of reference of said township of Hull and being the northwesterly part of the property conveyed to Archibald Taxes Noms Rang munie.Lots Names Range Munie.taxes 788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 conformément au document enregistré au bureau d'enregistrement de Gatineau sous le numéro 9244 et ladite propriété immobilière plus particulièrement décrite comme suit: Commençant sur la limited nord de ladite propriété Daugh-erty à une distance de cent vingt-trois pieds et sept dixièmes (123.7') mesurés au sud quatre-vingt-deux degrés, trente-cinq minutes ouest (S.82° 35' O.) au long de la ligne de clôture forimuit la borne nord de ladite propriété à partir du coin de la clôture sur la borne ouest du chemin Gatineau; de là.au sud quatre-vingt-deux degrés, trente-cinq minutes ouest (S.82° 35' O.), une distance de cent six pieds et deux dixièmes (106.2') le long de la clôture existante jusqu'au coin nord-ouest de ladite propriété Daugherty; de là, au sud treize degrés trente et une minutes ouest (S.13° 31' O.) une distance de soixante-dix-huit pieds et sept dixièmes jusqu'à un coin de clôture sur le côté nord d'un droit de passage nommé « The Mine Road ¦; de là, au sud soixante-quinze degrés quarante-neuf minutes est (S.75° 49' E.) une distance de cent treize pieds et cinq dixième s(113.5') le long d'une ligne de clôture représentant un coin de la propriété antérieurement vendue par Archibald Daugherty à E.Mulligan; de là.au nord quinze degrés vingt-sept minutes est (N.15° 27' E.) une distance deux pieds et trois dixièmes (2.3') jusqu'à un poteau de fer représentant un coin de ladite propriété Mulligan; de là, vers le nord soixante-dix-neuf degrés vingt-sept minutes est (N.79° 27' E.) une distance de vingt-huit pieds et sept dixièmes (28.7') le long de la borne nord de ladite propriété Mulligan; de là, au nord sept degrés dix minutes ouest (n.7° 7' O.) une distance de cent treize pieds (113') jusqu'au point de départ.Contenant onze mille pieds carrés (11,000 p.c.) de superficie, plus ou moins.Avec les bâtisses.Daugherty according to instrument registered at the Gatineau Registry Office under number 9244 and said immoveable more particularly described as follows : , Commencing on the northerly boundary of said Daugherty s property at a distance of one hundred and twenty-three feet seven tenths of a foot (123.7') measured south eighty-two degrees thirty-five minutes west (S.82° 35' W.) along the fence line forming the northerly boundary of said property from the fence corner on the westerly boundary of the Gatineau Highway; thence, south eight-two degrees thirty-five minutes west (S.82° 35' W.) a distance of one hundred and six feet and two tenths of a foot (106.2') along the existing fence line to the northwesterly corner of the said Daugherty's property; thence, south thirteen degrees thirty-one minutes west (S.13° 31' \\V.) a distance of seventy-eight feet and seven tenths of a foot (78.7') to a fence corner on the northerly side of a right of way called The Mine Road ; thence, south seventy-five degrees forty-nine minutes east (S.75° 49' E.) a distance of one hundred and thirteen feet and five tenths of a foot (113.5') along a fence line on the representing a corner of the property previously sold by Archibald Daugherty to E.Mulligan; thence, north fifteen degrees twenty-seven minutes east (N.15° 27' E.) a distance of two feet and three tenths of a foot (2.3') to an iron post representing a corner of the said Mulligan property; thence, northerly seventy-nine degrees twenty-seven-minutes east (N.79° 27' E.) a distance of twenty-eight feet and seven tenths (28.7') along the northerly boundary of the said Mulligan property; thence, north seven degrees ten minutes west (N.7° 10' W.) a distance of one hundred and thirteen feet (113') to the place of commencement.Containing eleven thousand square feet (11,000 sq.ft.) in area more or less.With buildings.Taxes Taxes Noms Rang munie.scol.Lots Total Names Range Munie.School taxes taxes Coderre, Hilaire.P.24.Un immeuble situé dans le canton de Hull, comté Gatineau, province de Québec, comprenant toute cette propriété connue et désignée comme étant formée d'une partie du lot vingt-quatre (P.24) du quinzième rang conformément aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Hull et ledit emplacement de forme irrégulière plus particulièrement décrit comme suit: Commençant à un point situé sur le côté ouest du Chemin du Moulin et ledit point de départ situé à trente pieds (30') au sud dudit Chemin du Moulin et du chemin privé; dudit point de départ dans une direction sud-est le long du côté ouest ou sud-ouest dudit Chemin du Moulin une distance de cent dix pieds (110') jusqu'à un point; de là, dans une direction sud une distance de soixante-dix pieds (70') jusqu'à un point; de là, dans une direction nord-ouest une distance de quatre-vingt-quinze pieds (95') jusqu'à un point situé sur le côté est du chemin privé ci-dessus rapporté; de là, daus une direction nord le long du côté est dudit chemin privé une distance de cent pieds (100') jusqu'à un point; de là, dans une direction est une distance de trente-trois pieds (33') de retour au point de départ.Avec lc3 bâtisses.Labelle, Gérard & Entreprise Valpin Reg'd.P.7B (3 u.o.).Un immeuble situé dans le canton de Hull, comté de Gatineau, division d'enregistrement de Gatineau, province de Québec, connu et désigné comme étant une partie du lot sept \u2022 B ¦ (P.7B) dans le septième rang, aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Hull, ladite parcelle de terrain indiquée par le numéro trois (3) sur le plan annexé à un acte de partage passé devant Me Jean-Guy Martel, notaire, le dix-huit octobre mil neuf cent soixante-sept, enregistré à Maniwaki sous le No 79370, et plus particulièrement décrit comme suit: Commençant à un point situé à quatre cent quatre-vingt-onze pieds et un dixième de pied (491.1') au sud de la limite sud du chemin HuU-Maniwaki, telle distance mesurée le long de la clôture séparant la propriété présentement décrite de celle de Patrick J.Hendrick ou représentant; de ce point dans une direction est longeant la limite sud de la propriété .16 t 502.26 S 602.26 An immoveable situate in the township of Hull, county of Gatineau, Province of Québec, consisting of all that property known and designaged as being formed of part of lot twenty-four (P.24) in the fifteenth range, according to the official plan and book of reference for the said township of Hull, and said emplacement of irregular figure more particularly described as follows : Commencing at a point located on the westerly side of Millroad and said commencing point situated at thirty feet (30') south from the fork of said millroad with the private road ; from said commencing point in a southeasterly direction along the westerly or southwesterly side of said millroad a distance of one hundred and ten feet (110') to a point; thence, in a southerly direction a distance of seventy feet (70') to a point; thence, in a northwesterly direction a distance of ninety-five feet (95') to a point located on the easterly side of the private road above referred to; thence in a northerly direction along the easterly side of said private road a distance of one hundred feet (100') to a point; thence, in an easterly direction a distance of thirty-three feet (33') back to the commencing point.With buildings.7 $ 6.60 20.70 26.20 An immoveable situated in the township of Hull, county of Oatineau, (jatineau Registration Division, Province of Québec, known and designated as being a part of lot seven \"B\" (P 7B> on the seventh range, in the official plan and book of reference of the said township of Hull, the said tract of land indicated by number three (3) on the plan appended to an act of partition of real property executed before Mr.Jean-Guy Martel, notary, on the eighteenth day of October, one thousand nine v£™a^J%*^\\?,*n*'l!utd in Maniwaki under No.79370, and more fully described as follows: Starting at a HSÎ n soml T,h»ndr,land 1™^:°™ «nd one tenth feet (491.1 ) south of the southern boundary of Hull-Maniwaki Road, such distance having been measured along tle fence separating the property now described from that of Patrick J.Hendrick or representatives; from this point in :,n e^uriy QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol 104, No.4 789 de M.Germain Jean-Venne, ou représentants, une distance de cent soixante-quinze pieds (175'J jusqu'à un point situé au coin sud-est de ladite propriété de M.Germain Jean-Venne ou représentant; de ce point dans une direction sud, une distance de cent quarante-neuf pieds et quatre dixièmes de pieds (149.4') jusqu'à un point; de ce point dans une direction ouest, une distance de cent soixante-quinze pieds (175') situé le long de la clôture séparant la présente propriété de celle de Patrick J.Hendrick ou représentant; de ce point dans une direction nord, longeant ladite clôture, une distance de cent quarante-neuf pieds et quatre dixièmes de pieds (149.4') jusqu'au point de commencement et le tout borné comme suit: au nord par partie du même lot, propriété de M.Germain Jean-Venne ou représentants; à l'est par une autre partie du même lot, propriété de Charles J.Hendrick ou représentants; au sud par une autre partie du même lot, propriété de M.Bernard Jean-Venne ou représentants et à l'ouest par une autre partie du même lot, propriété de Patrick J.Hendrick ou représentants.direction along the southern boundary of the property of Mr.Germain Jean-Venne or representatives, one hundred and seventy-five feet ( 175') to a point situated on the southeast corner of the said property of Mr.Germain Jean-Venne or representative; from this point in a southerly direction, one hundred and forty-nine and four tenths feet (149.4') to a point; from this point in a westerly direction, one hundred and seventy-five feet (175') situated along the fence separating this property from that of Patrick J.Hendrick or representative; from this point in a northerly direction along the said fence, one hundred and forty-nine and four tenths feet (149.4') to the starting point, the whole bounded as follows: on the north by part of the same lot belonging to Mr.Germain Jean-Venne or representatives; on the east by another part of the same lot belonging to Charles J.Hendrick or representatives; on the south by another part of the same lot, property of Mr.Bernard Jean-Venne or representatives and on the west by another part of the same lot belonging to Patrick J.Hendrick or representatives.Taxes Taxes Noms Rang munie.scol.Lots Total Names Range Munie.School taxes taxes Martineau, Florent.P.24., Un immeuble situé dans le canton de Hull, comté de Gatineau, province de Québec, division d'enregistrement de Gatineau, consistant en toute cette propriété connue et désignée comme étant formée d'une partie du lot vingt-quatre (P.24) dans le quinzième rang, aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Hull et ledit immeuble plus particulièrement décrit et borné comme suit: au nord par autre partie du même lot étant la propriété du Vital Renaud ou représentants telle que décrite aux termes d'un acte de vente reçu devant Me Pierre DesRosiers, notaire, le 5 avril 1961, sous le numéro 14,881 de ses minutes et dont copie enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Gatineau, sous le numéro 54,959 et au nord par un chemin privé et mesurant environ cent pieds (100'); à l'est par un chemin privé et mesurant environ soixante-quinze pieds (75'); au sud par autre partie du même lot étant la propriété de F.T.Cross ou représentants et mesurant environ cent pieds (100'); à l'ouest par autre partie du même lot étant la propriété de Raoul Gervais ou ses représentants et mesurant environ soixante-quinze pieds (76').Avec bâtisses.Renaud.Noël V.P.25C.1° Toute cette pièce ou parcelle de terrain mesurant cent pieds de largeur sur soixante-six pieds de profondeur, formant partie du lot vingt-cinq (25) < C > (P.25C) du 16e rang du canton de Hull, dans le comté de Gatineau, en la province de Québec, et bornée comme suit: Au sud par un chemin nommé le Chemin Mulvihill, à l'est et au nord par la propriété appartenant à Osborne Carman ou représentants.2° Une autre partie dudit lot numéro vingt-cinq (25) « C » (P.25-C) mesurant cent deux pieds (102') Sur le chemin Mulvihill sur soixante-dix pieds de profondeur sur la ligne est et quatre-vingtrquinze pieds sur la ligne ouest sur quatre-vingt-sept pieds de largeur en arrière et bornée comme suit: Au nord par la propriété de Osborne Carman ou représentants, à l'est par la propriété ci-dessus décrite, au sud par le chemin Mulvihill et à l'ouest par le résidu dudit lot, à distraire cette lisière de dix pieds de largeur sur le côté et vendue à J.H.Thornell ou représentants, ainsi qu'enregistré à Hull, sous le No 45176.15 % 469.15 % 469.15 An immoveable situated in the township of Hull, county of Gatineau.Province of Québec, Gatineau Registration Division, consisting of the entire property known and designated as being formed of a part of lot twenty-four (P.24) on the fifteenth range, in the official plan and book of reference of the township of Hull and the said immoveable more fully described and bounded as follows: On the north by another part of the same lot being the property of Vital Renaud or representatives as described in the terms of a deed of sale executed before Mr.Pierre DesRosiers, notary, on April 5, 1961, under number 14,881 of his minutes and a copy of which is registered at the Gatineau Registration Division Office, under number 54,959, and bounded on the north by a private road measuring about one hundred feet (100'); on the east by a private road measuring about seventy-five feet (75'); on the south by another part of the same lot being the property of F.T.Cross or representatives and measuring about one hundred feet (100'); on the west by another part of the same lot being the property of Raoul Gervais or representatives, measuring about seventy-five feet (75').With buildings.16 207.62 207.62 1.All that piece or parcel of land measuring one hundred feet in width and seventy-six feet in depth, being part of lot twenty-five (25) \"C\" (P.25C) in the sixteenth range of the township of Hull, in the county of Gatineau in the Province of Québec, and bounded as follows: Southerly by a road called Mulvihill's Road, easterly and northerly by property belonging to the Osborne Carman, or representatives.2.Another part of said lot number twenty-five (25)\"C\" (P.25C) measuring one hundred and two (102) feet on the MulvihiU's Road by seventy-six feet in depth on the east line and ninety-five feet on the west line, by eighty-seven feet in width in rear and bounded as follows: Northerly by the property of one Osborne Carman, or representatives, easterly by the property herein before described, southerly by the Mulvihill's road and westerly by the residue of said lot, less strip of ten feet in width on side sold to J.H.Thornell or representatives, as registered at Hull, under No.46175.Corporation municipale de Ste-Cécile-de-Masham \u2014 Canton de Masbam Municipal Corporation of Ste-Cécile-de-Masham \u2014 Township of Masham Bélanger, Roland.P.58.7 S 106.05 $ 118.42 % 224.47 Un lopin de terre connu et désigné comme étant partie du A piece of land known and designated as being part of lot numéro cinquante-huit du septième rang du canton de lot number fifty-eight of the seventh range of the township of 790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Masham; mesurant cent pieds (100') de large par toute la profondeur qu'il y a entre le chemin public et le lac; borné comme suit: au nord par le lac Bélisle.au sud par le chemin public, à l'est par cette partie du même lot propriété de Roland Bélanger ou représentants et à l'ouest par partie du même lot propriété de Roger Breton ou représentants.Masham measuring one hundred feet (100') in width by the entire depth between the public road and the lake, bounded as follows: on the north by Bélisle Lake, on the south by the public road, on the east by that part of the same lot belonging to Roland Bélanger or representatives and on the west by part of the same lot belonging to Roger Breton or representatives.\t\t\tTaxes\tTaxes\t Noms\tLots\tRang\tmunie.\tscol.\tTotal Names\t\tRange\tMunie.\tSchool\t \t\t\ttaxes\ttaxes\t Colombia Investment.P.61.Un emplacement sis à St-Louis de Masham, comté de Gatineau.province de Québec et connu comme étant partie du lot de terre numéro cinquante et un (P.51) du cadastre pour li- rung numéro quatre (R.IV) du canton de Masham.division d'enregistrement de Gatineau.dite Province, contenant cent cinquante pieds (150').de largeur sur le chemin public et en arrière sur une profondeur de deux cents pieds (200') mesures anglaises, tenant en avant en front au chemin public appelé chemin St-Louis de Masham, en arrière à partir du même lot, propriété de Dame Wilfrid Martineau ou représentants, d'un côté à partie du même lot.propriété de Gerain Renaud ou représentants, de l'autre côté à partie du même lot.propriété de ladite Dame Wilfrid Martineau ou représentants.Avec toutes les bâtisses, circonstances et dépendances.Gauthier, Marcel.58.Le lot numéro cinquante-huit (58) du rang lettre A, du canton de Masham, comté de Gatineau.Larocque, Émeril.P.64A.Un emplacement sis dans la municipalité de Ste-Cécile de Masham, comté de Gatineau, province de Québec, connu et désigné comme étant la partie nord-ouest du lot de terre numéro cinquante-quatre \u2022 A \u2022 (54A, P.) au cadastre officiel pour le rang numéro six (R.VI) du canton de Masham, division d'enregistrement de Gatineau, province de Québec, contenant cent vingt-sept pieds et six pouces (127'6\") de profondeur dans les lignes est et ouest sur toute la largeur qui existe entre la ligne de division des lots cinquante-cinq et cinquante-quatre « A > (55, 54A) et l'emplacement actuel de Paul Cloutier, fils, ou représentants, ce dernier dit emplacement consistant en la partie nord-est dudit lot cinquante-quatre « A » (54A.P.) soit, pour ladite largeur, une contenance d'environ trois (3) acres, plus ou moins, mesures anglaises, et tenant au nord en front à la ligne de division des rangs six et sept et au chemin public, à l'est à l'emplacement audit Paul Cloutier, fils, ou représentants, au sud en arrière au résidu du même lot, propriété de Godfroy Cloutier ou représentants, à l'ouest â la ligne de division des lots cinquante-cinq (55) et cinquante-quatre « A » (64A); Le tout, sujet à un droit de passage de vingt pieds (20') de largeur à l'extrémité ouest de l'emplacement présentement décrit, longeant la ligne de division des lots cinquante-cinq (55) et cinquante-quatre « A » (54A), pour aller audit chemin public en faveur dudit Godfroy Cloutier, ses successeurs et ayants-droit, tel que stipulé au titre d'acquisition de Émeril Larocque.Compris tous les bâtiments y élevés, circonstances et dépendances.Schnob, André.P.33.Un immeuble étant partie du lot trente-trois (P.33) du rang trois (R.III) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Masham, et plus particulièrement décrit comme suit: Partant d'un point situé sur la ligne de division des lots trente-quatre et trente-trois (34 et 33) dudit rang trois (II.III) canton de Masham.sis à une distance de cent vingt-cinq pieds (125') plus ou moins mesures anglaises, de la limite nord du Chemin du Roi, de ce point, à angle droit, allant dans une direction nord, longeant la ligne de division des lots trente-trois et trente-quatre (33 et 34) du rang trois (R.III) canton de Masham, mesures anglaises, de ce point, allant dans une .4 S 24.68 S 49.89 S 74.47 An emplacement situated at St-Louis de Masham, county of Gatineau.Province of Québec, known as being part of lot of land number fifty-one (P.51) of the cadastre for range number four (R.IV) of the township of Masham.Gatineau Registration Division, said Province, measuring one hundred and fifty feet (150') in width on the public road and in the rear by a depth of two hundred feet (200') English measure, bounded in front by the public road called St-Louis de Masham Road, in the rear of the said lot by the property of Mrs.Wilfrid Martineau or representatives, on one side partly by the same lot belonging to Gerain Renaud or representatives, on the other side partly by the same lot belonging to the said Mrs.Wilfrid Martineau or representatives.With all buildings, circumstances and dependencies.A 22.93 46.62 69.45 Lot number fifty-eight (58) of range letter A of the township of Masham, county of Gatineau.6 61.95 64.52 126.47 An emplacement situated in the municipality of Ste-Cécile de Masham, county of Gatineau, Province of Québec, known and designated as being the northwest part of lot of land number fifty-four \"A\" (54A, P.) on the official cadastre of range number six (R.VI) of the township of Masham, Gatineau Registration Division, Province of Québec, measuring one hundred and twenty-seven feet six inches (127'6\") in depth on its east and west lines by the entire width existing between the dividing line of lots fifty-five and fifty-four \"A (55.54A) and the present emplacement of Paul Cloutier Jr.or representatives, the latter said emplacement consisting in the northeast part of said lot fifty-four \"A\" (54A, P.) namely, for the said width, containing about three (3) acres, more or less, English measure, and bounded on the north, in front by the dividing line of ranges six and seven and the public road, on the east by the emplacement belonging to the said Paul Cloutier Jr.or representatives, on the south, in the rear by the remainder of the same lot belonging to Godfroy Cloutier or representatives, on the west by the dividing line of lots fifty-five (55) and fifty-four \"A\" (54A); The whole, subject to a right of way of twenty feet (20') in width at the western extremity of the emplacement now described, bordering the dividing line of lots fifty-five (65) and fifty-four \"A \" (54A) to the said public road in favor of the said Godfroy Cloutier.his successors and rightful claimants, as stipulated in the deed of purchase belonging to Emeril Larocque.All buildings erected thereon are included, circumstances and dependencies.3 66.81 315.28 382.09 An immoveable being part of lot thirty-three (P.33) of range three (R.Ill) in the official plan and book of reference of the township of Masham, more fully described as follows: Starting at a point situated on the dividing line of lots thirtv- îoUrt?TI\\d.thirtï*thl^ew of the 8a'd range three (K.Ill) township of Masham, situated at a distance of one hundred and twenty-five feet (125') more or less, English measure, from the northern boundary of Chemin du Roi, from this point, at right angles and in a northerly direction, Jg\"f yiJPîyfe» l,neuof Tots thirty-three and thirty-four (33 and 34) of Range three (R.Ill) township of Masham QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.U 791 direction eat, toute la distance qu'il y a de ce point jusqu'à un autre point situé à une distance de vingt pieds (20') plus ou moins, mesures anglaises, de la ligne de division entre les lots trente-trois et trente-deux (33-32) dudit rang trois (R.III) canton de Masham; de ce point, allant dans une direction sud, toute la distance qu'il y a de ce point jusqu'à la limite nord du Chemin du Roi, ce point étant situé à une distance de vingt pieds (20') plus ou moins, mesures anglaises du point d'intersection entre la ligne de division des lots trente-trois et trente-deux (33 et 32) dudit rang trois (R.III), du canton de Masham, et la limite nord [du Chemin du Roi; de ce point, allant dans une direction ouest, une distance de quatre cent trente pieds (430') plus ou moins, mesures anglaises jusqu'à la limite sud-est de la propriété de M.Henri Braseau ou représentant; de là, dans une direction nord, une distance de cent cinq pieds (105') plus ou moins, mesures anglaises, jusqu'à la limite nord-est de la propriété dudit M.Henri Braseau ou représentants; de là dans une direction ouest, une distance de deux cents quatre-vingt-douze pieds (292') plus ou moins, mesures anglaises jusqu'à la limite nord-ouest de la propriété de M.Adrien Le gros, ou représentants; de ce point, allant dans une direction nord, toute la distance qu'il y a jusqu'à un autre point situé, sur la limite nord-est de la propriété de M.Emile Gauvreau ou représentants; de ce point, allant dans une direction ouest toute la distance qu'il y a jusqu'au point de commencement; Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et non apparentes affectant ledit immeuble, particulièrement sujet aux servitudes mentionnées, aux ventes enregistrées audit bureau de la division de Gatineau, sous les numéros 33537 et 38916; Comprenant tous les bâtiments érigés, circonstances et dépendances.English measure, from this point, in an easterly direction, the entire distance from this point to another point situated at twenty feet (20') more or less, English measure, from the dividing line between lots thirty-three and thirty-two (33-32) of said range three (R.Ill) township of Masham; from this point, in a southerly direction, the whole distance from this point to the northern boundary of Chemin du Roi, this point situated at twenty feet (20') more or less, English measure, from the point of intersection between the dividing line of lots thirty-three and thirty-two (33 and 32) of said range three (R.Ill) of the township of Masham, and the northern boundary of Chemin du Roi; from this point, in a westerly direction, four hundred and thirty feet (430') more or less, English measure, to the southeastern boundary of the property of Mr.Henri Braseau or representative; thence, in a northerly direction, one hundred and five feet (105') more or less, English measure, to the northeastern boundary of the property of the said Mr.Henri Braseau or representatives; thence, in a westerly direction, two hundred and ninety-two feet (292') more or less, English measure, to the northwestern boundary of the property of Mr.Adrien Legros or representatives; from this point, in a northerly direction, the entire distance to another point situated on the northeastern boundary of the property of Mr.Emile Gauvreau or representatives; from this point, in a westerly direction the entire distance to the starting point; With and subject to all active and passive, apparent and un apparent servitudes affecting the said immoveable, particularly subject to the servitudes mentioned in the sales registered in the said Gatineau Division Office, under numbers 33537 and 38916; Including all buildings erected, circumstances and dependencies.Taxes Taxes Noms Rang munie.scol.Lots Total Names Range Munie.School taxes taxes Vaillancourt.Yvon.P.27.Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro vingt-sept (P.27), rang trois (R.III), du canton de Masham, comté de Gatineau, province de Québec, au cadastre officiel dudit canton, mesurant cent pieds (100') de largeur, ayant front sur le chemin public, sur toute la profondeur s'étendant dudit chemin public à la rivière La Pêche au sud et le tout borné comme suit: vers le nord par ledit chemin public; vers l'ouest par partie du même lot, appartenant à André Philippe ou représentants; au sud par la rivière La Pêche et à l'est par partie du même lot, propriété de M.Paul Vaillancourt ou représentants.McCaffrey, Florence et^ou-and/or McCaffrey P.13.Margaret.Toute cette parcelle de terrain connue et désignée comme étant formée d'une partie du lot treize (P.13) du troisième rang, conformément aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Masham, comté Gatineau, province de Québec et ladite parcelle de terrain étant plus particulièrement décrite comme suit: Commençant à un point qui coïncide avec le coin nord-est de la propriété de Mme Michael McKenna ou représentants, ainsi que décrite dans un acte de vente exécuté devant Me Pierre DesRosiers, notaire, le onzième jour de septembre 1963, sous le numéro 17470 de ses dossiers et enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Gatineau le 24e jour d'octobre 1963, sous le numéro 63425; dudit point de départ dans une direction sud le long de la limite est de la propriété de Mme McKenna ou représentants, une distance de deux cent cinq pieds (205') plus ou moins, jusqu'à un point situé sur la limite nord d'un chemin privé et ledit point coïncidant avec le coin sud-est de la propriété de Mme McKenna ou représentants; de là, dans une direction est le long de la limite nord dudit chemin privé, une distance de cent vingt-trois pieds (123'), plus ou moins, jusqu'à un point; de là, dans une direction nord, une distance de cent quarante cinq pieds (145') jusqu'à un point situé sur la rive sud du lac .3 $ 62.62 S 256.99 $ 309.61 An immoveable known and designated as being part of lot number twenty-seven (P.27), range three (R.Ill) of the township of Masham, county of Gatineau, Province of Québec, on the official cadastre of the said township, measuring one hundred feet (100') in width, fronting on the public road by all the depth extending from the said public road to Rivière La Pêche on the south, the whole bounded as follows: On the north by the said public road; on the west by part of the same lot belonging to André Philippe or representatives; on the south by Rivière La Pêche and on the east by part of the same lot, property of Mr.Paul Vaillancourt or representatives.3 13.66 21.20 34.85 All that parcel of land known and designated as being formed of part of lot thirteen (P.13) in the third range according to the official plan and book of reference for the township of Masham, county of Gatineau, Province of Québec and said parcel of land being more particularly described as follows: Commencing at a point coinciding with the northeast corner of the property of Mrs.Michael McKenna or representatives, as described in a deed of sale executed before Me Pierre DesRosiers, notary, on the 11th day of September 1963, under number 17470 of his records and registered at the Registry Office, Gatineau Division, on the 24th day of October 1963, under number 63425; from said commencing point in a southerly direction along the easterly limit of the property of Mrs.McKenna or representatives, a distance of two hundred and five feet (205') more or less, to a point located on the northerly limit of a private road and said point coinciding with the southeast corner of the property of Mrs.McKenna or representatives; thence, in an easterly direction along the northerly limit of the said private road, a distance of one hundred and twenty-three feet (123') more or less, to a point; thence, in a northerly direction a distance of one hundred and forty-five feet (145') to a point located on the south shore of Fraoer Lake; 792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Fraser; de là, dans une direction ouest une distance de cent sept pieds (107') le long de la rive du lac Fraser; de retour au point de départ et le tout borné comme suit: Au nord par le lac Fraser; à l'ouest par une autre partie du même lot, étant la propriété de Mme McKenna ou représentants, au sud ou sud-est par le chemin privé ci-dessus mentionné et à l'est par une autre partie du même lot, propriété de M.Errol Cross ou représentants.Comprenant aussi l'usage d'un droit de passage actuellement emprunté aux fins de communiquer de l'emplacement décrit au chemin public.thence, in a westerly direction a distance of one hundred and seven feet (107') along the shore of Fraser Lake, back to the commencing point and the whole bounded as follows: northerly by Fraser Lake; westerly by another part of the same lot, being the property of Mrs.McKenna or representatives; southerly or southeasterly by the private road above referred to and easterly by another part of same lot, property of Mr.Errol Cross or representatives.It also includes the use of a right-of-way as actually travelled to communicate from the emplacement described to the public road.Corporation municipale de Hincks \u2014 Canton de Hincks Municipal Corporation of Hincks \u2014 Township of Hincks Taxes Taxes Noms Rang munie.scol.Lota Total Names Range Munie.School taxes taxes Gauthier, Toussaint.P.30A.Toute cette partie de terrain mesurant cinquante-huit pieds de largeur par cent quarante-huit pieds de profondeur, le tout plus ou moins, et faisant partie du lot numéro trente « A > (P: 30A) dans le quatrième rang dudit canton de Hincks, tel que connu et désigné au plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour ledit canton de Hincks et borné comme suit: En front, à l'est au nouveau chemin public à être ouvert sur ledit terrain, au sud à cette partie du lot vendue à la Commission Scolaire, des autres côtés, au résidu dudit lot.Belair Royal.21-22 Environ 200 acres de terre sans bâtisse.4 8 18.40 8 104.85 8 123.25 All of this part of land measuring fifty-eight feet in width by one hundred and forty-eight feet in depth, the whole more or less, and forming part of lot number thirty \"A\" (P.30A) in the fourth range of the said township of Hincks, as known and designated on the official plan and book of reference of the cadastre of the said township of Hincks and bounded as follows: In front, on the east by the new public road to be opened on the said land, on the south by that part of the lot sold to the School Board, on the other sides by the remainder of the said lot.10 52.60 110.20 162.80 About 200 acres of land without buildings.Corporation municipale de Deleage \u2014 Canton de Kensington Municipal Corporation of Deleage \u2014 Township of Kensington Babineau, Mme-Mrs.Isidore, née-born Adèle P.19.Henri.Une partie du lot de terre portant le numéro 19, rang 2, du canton de Kensington; laquelle partie mesure cent quatre-vingt-huit pieds (188') en front sur le chemin public à l'ouest; la même chose à l'arrière, par une profondeur de cent trente-huit pieds (138') et laquelle partie est bornée comme suit, savoir: Vers le nord par la propriété de Joseph Morin ou représentants, vers l'ouest par le chemin public et vers le sud et l'est par partie du même lot, restant la propriété de Dame Alberta Morin épouse de Leopold Barbe ou représentants.Tel que le tout se trouve actuellement avec toutes les servitudes actives et passives apparentes et occultes attachées audit immeuble.Beaudoin, Henri.P.34-A.Une partie du lot de terre portant le numéro 34A non-sub-divisé dans le premier rang du canton de Kensington, laquelle partie de terrain mesure quatre-vingt pieds dans la ligne nord et sud par une profondeur de soixante-quinze pieds dans lés lignes est et ouest et bornée comme suit, savoir: Au nord par partie du même lot appartenant à Charles Robert Dufour.ou représentants, à l'ouest par la rue portant le numéro 34A-1, même rang et canton, et au sud et à l'est par partie du même lot restant la propriété du vendeur, avec bâtisses dessus érigées.Tel que le tout se trouve actuellement avec toutes les servitudes actives et passives apparentes ou occultes attachées audit immeuble.2 8 26.16 S 51.79 8 77.95 A part of the lot of land number 19, range 2, of the township of Kensington, the said part measuring one hundred and eighty-eight feet (188') in front on the public road on the west, the same in the rear, by a depth of one hundred and thirty-eight feet (138'), the said part bounded as follows, namely: On the north by the property of Joseph Morin or representatives, on the west by the public road, and on the south and east by part of the same lot, remaining the property of Mrs.Alberta Morin, wife of Leopold Barbe or representatives.As the whole now subsists, with all active and passive, apparent and unapparent servitudes attached to the said immoveable.1 122.32 92.57 214.89 A part of the lot of land numbered P.34A non-subdivided in the first range of the township of Kensington, the said part of land measuring eighty feet on the north and south line by a depth of seventy-five feet on its east and west lines and bounded as follows, namely: On the north by part of the same lot belonging to Charles Robert Dufour or representatives, on the west by the street numbered 34A-1, same range, and township, and on the south and east by part of the same lot remaining the property of the vendor, with buildings erected thereon.As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attached to the said immovable. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, A'o.4 793 Noma Names Lots Rang Range Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total Poirier, Rolland.P.34-A.Une partie du lot de terre portant le numéro trente-quatre A (P.34-A) dans le premier rang du canton de Kensington, laquelle partie de terrain mesure cent quarante et un pieds plus ou moins dans la ligne du côte nord, quatre-vingt-huit pieds (88') plus ou moins dans le ligne du côté sud, cent cinquante-cinq pieds (155')) plus ou moins dans la ligne du côté est, et cent quinze pieds (115') plus ou moins dans la ligne du côté ouest, et laquelle partie est bornée comme suit: savoir: Vers le nord par la propriété de monsieur Cousineau ou représentants et par la rue portant le numéro deux, vers le sud par la rivière Gatineau, vers l'ouest, par partie du même lot occupée par Paul-Aimé Séguin ou représentants, vers l'est par partie du même lot restant la propriété du vendeur.Avec maison dessus érigée circonstances et dépendances, Tel que le tout se trouve actuellement avec toutes les servitudes actives et passives apparentes ou occultes attachées audit immeuble.1 $ 174.07 S 96.42 $ 270.49 A part of the lot of land numbered thirty-four A (P.34-A) in the first range of the township of Kensington, the said part of land measuring one hundred and forty-one feet, more or less, in the line on the north side, eighty-eight feet (88'), more or less, in the line on the south side, one hundred and fifty-five feet (155'), more or less, in the line on the east side, and one hundred and fifteen feet (115'), more or less, in the line on the west side, the said part bounded as follows: namely: On the north by the property of Mr.Cousineau or representatives and by the street numbered two, on the south by Gatineau River, on the west by part on the same lot occupied by Paul-Aimé Séguin or representatives, on the east by part of the same lot remaining the property of the vendor, With a house erected thereon, circumstances and dependencies.As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attached to the said immoveable.Corporation municipale de Lytton \u2014 Canton de Lytton et Mitchell Municipal Corporation of Lytton \u2014 Township of Lytton and Mitchell Robillard, René.31.Améliorations seulement.4 ! Lyt.Improvements only.14.75 8 13.75 S 28.50 Corporation municipale du canton de Low \u2014 Canton de Low Municipal corporation of the township of Low \u2014 Township of Low Marlott, Baptiste.36 & 37.Succ.-est.Charles Stevenson.P.37E.Une propriété immobilière connue et désignée comme étant une partie du lot numéro trente-sept « E > (P.37E) rang deux (2), canton de Low, province de Québec, au cadastre officiel dudit canton, mesurant cent quatre pieds (104') de largeur sur deux cent trente pieds (230') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit: Au sud par un chemin municipal, à l'est par une partie du même lot appartenant à William Dodd ou représentants; à l'ouest par une partie du même lot appartenant à M.E.A.St-Jean ou représentants et au nord par le résidu du même lot appartenant à Dame Frances Eva Brooks ou représentants; ainsi que le tout subsiste présentement ; su jet à toutes et chacune des servitudes actives et passives apparentes existantes sur ou à l'encontre de ladite propriété; sauf et excepté un triangle de terrain sur le côté nord-est de l'emplacement ci-dessus décrit et vendu à la Reine (Ministère de la Voirie de la province de Québec).B t 30.70 S 136.04 $ 166.74 .2 4.00 14.30 18.30 An immoveable known and described as being part of lot number thirty-seven \"E\" (P.37E) range two (2) township of Low, province of Québec, at the official cadastre of said township, measuring one hundred and four feet (104') wide by two hundred and thirty feet (230') deep, English measure, more or less and bounded as follows: southerly by a municipal road, easterly by part of the same lot, belonging to William Dodd or representatives; westerly by part of the same lot, belonging to Mr.E.A.St-Jean or representatives and northerly by the residue of the same lot, belonging to Dame Frances Eva Brooks or representatives; as the whole now is; subject to all and any servitudes, active and passive, apparent or otherwise existing on or against the said property; save and except a triangle on the northeast side of the place above described sold to the Queen (Department of Roads of the Province of Québec).Corporation municipale du canton de Masham Nord \u2014 Canton de Masham Municipal Corporation of the township of Masham North \u2014 Township of Masham Foubert, Larry.P.9.Un immeuble situé dans le canton de Masham, comté Gatineau, province de Québec, comprenant toute cette propriété connue et désigné comme étant formée d'une partie du lot neuf (P.9) du cinquième rang conformément aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Masham, et ladite parcelle de terrain mesurant cent pieds (100') sur sa limite ouest vis à vis le lac Jemison, et cent pieds (100') sur sa limite est le long d'un chemin privé qui est un droit de passage établi en servitude exécutée devant le notaire, dont une copie dûment enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Gatineau, sous le numéro 36462, sur l'entière profondeur qui existe entre ledit chemin privé et ledit lac Jemison (approxi- .5 S 59.00 S 224.69 $ 283.69 An immoveable situate in the township of Masham.county of Gatineau, province of Québec, consisting in all that property known and designated as being formed of part of lot nine (P.9) in the fifth range according to the official plan and book of reference of said township of Masham, and said parcel of land measuring one hundred feet (100') in its westerly limit facing Lake Jemison, and one hundred feet (100') in its easterly limit along a private road being a right of way created in a servitude executed before the notary, copy duly registered at the registry office.Gatineau Division, under mlmber 36462, by the whole depth existing between said private road and 9aid Lake Jemison (approximately one hundred and forty-five 794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10k' année, n° k mativement cent quarante-cinq pieds (145'), mesures anglaise et plus ou moins, sans garantie de précision) ; ladite parcelle de terrain bornée comme suit: A l'ouest par le lac Jemison susmentionné; à l'est par le chemin privé ci-dessus mentionné; au nord par une autre partie du même lot, propriété d'Emile Robert ou représentants; au sud par une autre partie du même lot, propriété de N.J.McKeown ou représentants, selon description dans un acte devant le notaire et dont une copie a été dûment enregistrée au bureau d'enregistrement de là division de Gatineau, à Maniwaki, sous le numéro 42341.Ensemble avec un droit de passage en faveur du propriétaire (Foubert, Larry), ses ayants droit, ses amis et membres de sa famille, conjointement avec toutes les autres parties intéressées, aux fins de communiquer du chemin public à l'emplacement présentement décrit et ledit droit de passage tel que décrit dans l'acte de servitude ci-dessus rapportée et enregistré sous le numéro 36462 au bureau d'enregistrement de la division Gatineau, à Maniwaki.feet (145').English measures more or less, without warranty as to precise measurements); and said parcel of land bounded as follows: westerly, by Lake Jemison aforesaid; easterly, by the private road above mentioned; northerly, by another part of the same lot, being the property of Emile Robert or representatives; southerly, by another part of the same lot, being the property of N.J.McKeown or representatives, as described in a deed before notary and copy duly registered at the registry office, Gatineau Division, at Maniwaki, under number 42341.Together with a right of way in favour of owner (Foubert Larry), his assigns, his friends and members of his family, jointly with all other interested parties, to communicate from the public road to the emplacement presently described and said right-of-way as described in the above referred deed of servitude registered under number 36462 at the registry office, Gatineau Division, at Maniwaki.Corporation municipale du canton de Denholm \u2014 Canton de Denholm_ Municipal Corporation of the township of Denholm \u2014 Denholm township Taxes Taxes Noms Rang munie.scol.Lots Total NameB Range Munie.School taxes taxes Nash, Henry.23.E $ 66.01 S 184.28 $ 250.29 Bâtiments seulement (Chalet).Buildings only (Cottage).Constantineau, Ernest.13.E 39.57 153.96 193.53 Bâtiments seulement (Chalet).Buildings only (Cottage).Lavorie, Edward.13.E 66.10 205.00 270.10 Bâtiments seulement (Chalet).Buildings only (Cottage).Lover.Maurice.46.F 88.05 298.81 396.86 Bâtiments seulement (Chalet).Buildings only (Cottage).Paquette, Wilfred.11.E 30.79 102.86 133.67 Bâtiments seulement (Chalet).Buildings only (Cottage).Rochon, Armand.17.F 249.61 249.61 Toutes les bâtisses, circonstances et dépendances érigées AU the buildings, circumstances and dependencies, erected sur cette propriété située sur le lac Rond, connu et désigné on this property situated on Rond Lake, known and designated comme étant le lot numéro dix-sept (17) Rang F (R.F) aux as being lot number seventeen (17) range F (R.F) in the offi- plan et livre de renvoi officiels pour le canton de Denholm cial plan and book of reference of the township of Denholm ainsi que tous les droits qu'il peut y avoir sur le terrain, tel and all the rights which affecting the land, as purchased under qu'acquis sous bail numéro 10602 du Ministère des Terres et lease number 10602 of the department of lands and forests Forêts de la province de Québec.of the province of Québec.Corporation municipale du canton d'Aumond \u2014 Canton Aumond Municipal corporation of the township of Aumond \u2014 Township of Aumond Danis, Wilbrod.Mme-Mrs.& Héritiers-Heirs.6.6, 7.Avec bâtisses, circonstances et dépendances y érigées.Larche, Richard.P.16F.Un terrain faisant partie du lot 16F dans le rang I, au cadastre officiel du canton Aumond, situé sur le côté sud-est du chemin public qui passe sur le lot, mesurant 60' de largeur en front sur le chemin public, sur cent pieds de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins, et borné en front vers le nord-ouest par le chemin public, vers le sud-est par le lot 16A, d'un côté, vers le nord-est par une autre partie du même lot 16 « F ¦ appartenant à Dame Henri Roy ou représentants et de l'autre côté vers le sud-ouest par un passage faisant partie du susdit lot 16A et réservé pour communiquer du chemin public au lot 16A.Il faut distraire de ce terrain la partie vendue à Sa Majesté la Reine aux droits de la province de Québec.A 8 164.40 8 151.29 8 315.69 With buildings, circumstances and dependencies erected thereon.1 99.06 245.23 344.29 A piece of land being part of lot 16F in range I on the official cadastre of the township of Aumond.situated on the southeast side of the public road which crosses the lot.measuring 60' in width in front on the public road by one hundred feet in depth, English measure, more or less, and bounded in front on the northwest by the public road, on the southeast by i : ,o :.?.n,onc,sl ¦ on the northeast by another part of same lot 16 S belonging to Mrs.Henri Roy or representatives and on the other side on the southwest by a passage being part of the aforesaid lot 16A and reserved to communicate from the public road to lot 1GA.The part sold to Her Majesty the Queen for the province of Québec must be withdrawn. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.k 795 Taxes Taxes Noms Rang munie.scol.Lots Total Names Range Munie.School taxes taxes Larche, Richard.P.23B.Une partie de lot de terre portant le numéro 23B dans le premier rang du canton Aumond, laquelle partie de terrain mesure 100' de front à l'est sur le Lac Joseph, 150' à l'arrière à l'ouest sur le chemin public et borné comme suit: vers l'est par ledit Lac Joseph, vers l'ouest par ledit chemin public, vers le sud par le résidu dudit lot appartenant à Hector St-Amour ou représentants.Sans bâtisses.Lapratte, Alfred.P.6B.Un morceau de terrain sur le lot 6B, R.B, environ 50' sur le lac écarté sur une profondeur de cent pieds avec bâtisses dessus érigées.Lefebvre, Wilfrid.54.Bâtisse seulement.Michaud, Ferdinand.12.100 acres de terre avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.Michaud, Ferdinand.K.10,11.200 acres de terre avec bâtisses dessus érigées circonstances et dépendances.Michaud, Ferdinand.40.100 acres de terre.Michaud, Gustave.44, 45A.150 acres de terre avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.Michaud, Gustave.43.101 acres de terre.Michaud, Gustave.44B.47 acres de terre.aquette, Wilbur.94.0.96 acres, chalet d'été (villa), et tous bâtiments, circonstances et dépendances, dessus érigés.Labelie, Lucien.P.17J.Un terrain ou emplacement faisant partie du lot numéro dix-sept J (P.17J) du premier rang (R.I) du canton Aumond, suivant le plan officiel de ce canton, situé au sud-ouest du chemin public, mesurant soixante-dix pieds (70') de largeur au nord-est en front sur ce chemin public ainsi qu'à l'arrière vers le sud-ouest, par une profondeur de cent cinquante-huit pieds (158') dans les lignes nord-ouest et sud-est, et ainsi borné: en front au nord-est par le chemin public, à l'arrière vers le sud-ouest par le résidu dudit lot appartenant à Leopold Céré ou représentants, d'un côté au sud-est par partie dudit lot dix-sept « J > (P.17J) appartenant au vendeur, et de l'autre côté au nord-ouest par la propriété de Leopold Céré ou représentant, sans bâtisse.1 S 6.90 S 24.64 $ 31.54 A part of the lot of land numbered 23B in the first range of the township of Aumond, the said part of land measuring 100' in front on the east by Joseph Lake, 150' in the rear on the west by the public road and bounded as follows: on the east by the said Joseph Lake, on the west by the said public road, on the south by the remainder of the said lot belonging to Hector St-Amour or representatives.Without buildings.B 20.37 40.86 61.23 A piece of land on lot 6B, R.B.about 50' on Ecarté Lake by a depth of one hundred feet with buildings erected thereon.13.42 11.63 25.05 Building only.\u201e.4 36.00 138.57 174.57 100 acres of land with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.3 11.85 46.62 58.47 200 acres of land with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.6.15 28.68 34.83 100 acres of land.4 63.63 91.50 155.13 150 acres of land with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.101 acres of land.13.83 15.58 22.76 23.14 36.59 38.72 47 acres of land.D 17.32 106.31 123.63 0.96 acres, summer chalet (villa), and all buildings, circumstances and dependencies erected thereon.1 16.25 16.25 A piece of land or emplacement being part of lot number seventeen J (P.17J) of the first range (R.1) of the township of Aumond, according to the official plan of this township, situated southwest of the public road, measuring seventy feet (70') in width on the northeast in front by this public road and in the rear on the southwest by a depth of one hundred and fifty-eight feet (158') on the northwest and southeast lines, and bounded thus: in front on the northeastb by the public road, in the rear on the southwest by the remainder of the said lot belonging to Leopold Céré or representatives, on one side on the southeast by part of said lot seventeen\"J\" (P.17J) belonging to the vendor, and on the other side on the northwest by the property of Leopold Céré or representative, without buildings.Corporation municipale de Bois-Franc \u2014 Canton de Egan Municipal Corporation of Bois-Franc \u2014 Township of Egan Ethier.Roger F.61,62,63,64.B S 262.79 S 262.79 Larche, Alfred, succ.-est.P.54.1 55.63 55.63 Partie du lot 54, rang I, Egan, borné au nord par le lot 55, Part of lot 54, range 1, Egan, bounded on the north by lot appartenant à Emile Lafontaine ou représentants et partie 55 belonging to Emile Lafontaine or representatives and part du lot 54 appartenant à Jean-Marie Mercier ou représentants, of lot 54 belonging to Jean-Marie Mercier or representatives. 796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i' année, n° U a l'ouest par la route No 11 et partie du lot 54, appartenant à Jean-Marie Mercier ou représentants, au sud par lot 53 appartenant à Gervais Carrière ou représentants, à l'est par lot 54 rang B, concession de la C.I.P.on the west by Highway No.11 and part of lot 54 belonging to Jean-Marie Mercier or representatives, on the south by lot 53 belonging to Gervais Carrièfe or representatives, on the east by lot 54, range B, C.I.P.concession.\t\t\t\tTaxes\tTaxes\t Noms\t\t\tRang\tmunie.\tscol.\tTotal \t\tLots\t\t\t\t Names\t\t\tRange\tMunie.\tSchool\t \t\t\t\ttaxes\ttaxes\t \t.35.\t\t1\tI 28.60\t8 145.37\t8 173.87 Donné à Gracefield, au bureau de la Corporation du comté de Gatineau, ce 1er jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44036-o Harold Kelly.Given at Gracefield, at the Office of the Corporation of the county of Gatineau, this 1st day of January, 1972.Harold Kelly, 44036 Secretary-Treasurer.Municipalité du comté de Berthier Avis public est par les présentes donné par Me J.-D.Giroux, secrétaire-trésorier, que les terrains ci-après décrits seront vendus à l'enchère public, au Palais de Justice de Berthierville, au No 180 de la rue Cham-plain, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi pour taxes municipales et scolaires dues, à moins que cesdites taxes et frais encourus ne soient payés avant le jour ci-dessus désigné.Municipality of the County of Berthier Public notice is hereby given by Mr.J.-D.Giroux, Secretary-Treasurer, that the lands hereinafter described will be sold bv public auction at the Berthierville Court House, 180 Champlain Street, on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon for municipal and school taxes due, unless the said taxes and costs incurred are paid before the abovementioned date.Municipalité de Saint-Michel des Saints \u2014 Municipality of Saint-Michel des Saints Propriétaires Owners\tCadastre Lots\tTaxes munie, et int.Munie, taxes and int.\tTaxes scol.et int.School taxes and int.\t\tS 24.41\t$ 76.35 334.80 26.32 20.43 \t.Cant, de-towns, of Provost.P.53, P.52, rg.VI.\t\t Satacousse, succ.-est.Harris.\tS.E.\t2.60\t Municipalité de Saint-Zénon \u2014 Municipality of SaintZénon\t\t\t Germain, Jean-J.Cant, de-towns, of Courcelles Bertrand, Jean.Cant, de-towns, of Courcelles Sullivan, Gordon Edward.Cant, de-towns, of Courcelles Vachon.Pierre.Cant, de-towns, of Provost.L'Heureux Domaine Ltée, a/s-c/o Cant, de-towns, of Provost.Comeau J.-Guy.Huot, Gilles.Cant, de-towns, of Courcelles P.7-D-3.rg.5.P.34-C.rg.2.P.42-A, rg.1.P.39.rg.P.P.13.rg.13.7-D-2, rg.5.46.00 3.30 6.90 4.40 124.84 18.94 18.94 20.32 137.44 137.13 Municipalité de Saint-Damien de Brandon \u2014 Municipality of Saint-Damien de Brandon Baribeau, Etienne.Cant, de-towns, of Gauthier.Beaupré, André.Par.de-of St-Damien de-of Brandon.Belisle, Rosario.Cant, de-towns, of Gauthier.Blain, Lionel.Par.de-of St-Damien de-of Brandon.23, rg.A.317-318-272-273, rg.12.97, rg.A.302.rg.12________ S 6.60 4.76 61.18 8 25.90 131.61 21.72 164.42 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.1 797 \t\t\tTaxes\tTaxes \t\t\tmunie\t8C0l.Propriétaires\t\t\tet int.\tet int.\tCadastre\tLots\t\t Owners\t\t\tMunie.\tSchool \t\t\ttaxes\ttaxes \t\t\tand int.\tand int.Brûlé, Pierre.\t\t13, rg.A.\tS 5.02\t8 23.11 \t\t313, rg.12.\t\t139.52 \tBrandon.\t\t\t \t\t152A,rg.9.\t20.49\t22.94 \tBrandon.\t\t\t \t\t313 nr 12 .\t16 20\t42.41 \tBrandon.\t\t\t \t\tP 264, rg 11.\t122.97\t469.95 \tBrandon.\t\t\t \t\t\t82.47\t173.72 \tBrandon.\t\t\t \t\t25, rg.A.\t6.98\t10.58 \tBrandon.\t\t\t \t\t\t\t37.82 \tBrandon,\t\t\t \t\t121, rg.10.\t11.37\t25.90 \tBrandon.\t\t\t \t\t\t\t69.22 \tBrandon.\t\t\t \t\t\t17.82\t32.05 \tBrandon.\t\t\t Lacbapelle, Mme-Mrs.Thérèse.\t.Par.de-of St-Daraien de-of\tP.139, rg.10.\t8.44\t28.65 \tBrandon.\t\t\t \t\t312, rg.12.\t62.61\t337.53 \tBrandon.\t\t\t \t\t112, rg.A.\t4.76\t22.34 \t.Par.de-of St-Daraien de-of\tP.313, rg.12.\t92.72\t110.25 \tBrandon.\t\t\t \t.Par.de-of St-Damien de-of\t\t\t133.11 \tBrandon.\t\t\t \t\tP.171, rg.10.\t\t93.54 \tBrandon.\t\t\t \t\t225.\t\t42.40 \tBrandon.\t\t\t \t\tP.326.\t2.40\t9.87 \tBrandon.\t\t\t \t\tP.120, rg.10.\t\t36.60 \tBrandon.\t\t\t \t\tP.312, rg.12.\t\t411.73 \tBrandon.\t\t\t \t\tP.152-B.rg.9.\t3.45\t15.19 \tBrandon.\t\t\t Paquette, Ghislaine.\t____ Cant, de-towns, of Gauthier.\t72, rg.A.\t14.04\t38.79 \t\tP.3.rg.7.\t\t6.42 \tBrandon.\t\t\t \t\tP.170, rg.11.\t80.70\t189.49 \tBrandon.\t\t\t \t\tP.305, rg.12.\t31.27\t86.42 \tBrandon.\t\t\t \t\t140, rg.A.\t19 98\t62 53 \t\t139, rg.A.\t16.21\t39.53 Tardif, Gérard.\t\tP.152, rg.9.\t\t15.19 \tBrandon.\t\t\t \t\tP.152B, rg.9.\t\t71.71 \tBrandon.\t\t\t \t\t\t10.17\t22.40 Brandon.Municipalité de Saint-Charles de Mandeville \u2014 Municipality of Saint-Charles de Mandeville Chevrette, Viateur.\t____ St-Didace, par.\t12, 2e-nd N.E.P.8\t41.94 8\t24.05 \t\tP.6, 2e-nd N.E.P.\t23.94\t51.00 Giroux, Rolland.\t____ Par.de-of St-Gabriel de-of\tP.25, A.E.P.\t19.19\t17.47 \tBrandon.\t\t\t \tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.350, Lac-Lake Long\t26.97\t44.76 \tBrandon.\t\t\t \tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.113, rg.St-Pierre.\t90.15\t215.26 \tBrandon.\t\t\t 79S GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Propriétaires Owners Cadastre Lots Taxes munie, et int.Munie, taxes and int.Taxes ¦col.et int.School taxes and int.Mondor.Lucien.Par.de-of St-Didace.P.16, A.E.P.Moore, Gordon.Par.de-of St-Didace.P.702, Lac-Lake Mandeville.Paradis, Clément.Par.de-of St-Didace.P 356, Lac-Lake Long Bergeron, Euclide succ.-est.Par.de-of St-Didace.P.C, 5, N.E.P.38.31 7.71 6.81 29.41 S 129.88 18.80 9.35 67.07 Municipalité de Saint-Gabriel de Brandon (paroisse) \u2014 Municipality of Saint-Gabriel de Brandon (parish) Boiavert, Paul-Emile.\tPar.de-of St-Gabriel de-of\t457.p.669.p.496-A.\tS\t630.22 \tBrandon.\t4e-th rg.\t\t \tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.139.p.618.\t\t306.81 \tBrandon.\trg.St-Jean.\t\t \tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.225, rg.St-David .\t\t25.89 \tBrandon.\t\t\t26.74 \tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.536, 6e-th Terrasse 8\t1.81\t \tBrandon.\tde Luxe.\t\t \tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.138, Domaine\t\t36.66 \tBrandon.\tBruneau.\t\t \tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.143, rg.St-Jean____\t\t45.50 \tBrandon.\t\t\t \tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.539, p.612,\t\t141.85 \tBrandon.\t6e-th rg.\t\t Morin, Hervé.^.\tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.583, 6e-th rg.\t\t134.37 \tBrandon.\t\t\t Nantel, Guy (Mme-Mrs.Jeanne-D'Arc\tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.539-B, 6e-th rg.\t7.76\t127.76 Côté).\tBrandon.\t\t\t Poulin, Stanilas.\tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.632, Ch.du Lac Rd\t\t327.86 \tBrandon.\t\t\t Richard, Aldor.\tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.544, Petit rg.5____\t\t108.18 \tBrandon.\t\t\t \tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.139-140, Chemin du\t17.41\t623.47 \tBrandon.\tLac, rue Lefrançois.\t\t Tremblay, Paul.\tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.558, P.508,\t\t248.16 \tBrandon.\t5e-th N.\t\t Turcotte, Mme-Mrs.Orner & Boucher,\tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.396.Ch.des lots.\t\t20.50 Marie-Laure.\tBrandon.\t\t\t Visoki, Franki.\tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.225, rg.St-David.\t\t36.12 \tBrandon.\t\t\t \tPar.de-of St-Gabriel de-of\tP.136-A, rg.St-Jean.\t3.62\t40.38 \tBrandon.\t\t\t Municipalité de Lanoraie D'Autray (paroisse) \u2014 Municipality of Lanoraie D'Autray (parish) Larjierre, Maurice.Par.de-of Lanoraie.P.96.8 40.34 S 158.76 McKee, Omer.Par.de-of Lanoraie.681-682-683.16.75 Pigeon, Mme-Mrs.Aurore Poirier.Par.de-of Lanoraie.P.439-P.440.71.62 166.97 Poupart, Georges.Par.de-of Lanoraie.108-1.47.60 82.22 Courville.Maurice & Boucher, Georges.Par.de-of Lanoraie.366-P.114.12 Masse, Délium.Par.de-of Lanoraie.1049.9.19 Rondeau, Julien.Par.de-of Lanoraie.647-648-649 .406^00 Municipalité de Saint-Joseph de Lanoraie (village) \u2014 Municipality of Saint-Joseph de Lanoraie (village) Roy, René.Par.de-of Lanoraie.169-P.$ 438.46 Leclerc, Mme-Mrs.Cécile.Par.de-of Lanoraie.118-P.$ 63.22 Municipalité de Saint-Norbert \u2014 Municipality of Saint-Norbert Clermont, Alphir.Lafrenière, Mélanie (Ducharme) Par.de-of St-Norbert Par.de-of St-Norbert P.147 388.8 0.84 3.00 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January\t29, 1972, Vol.104, No.\t4\t799 \t\tTaxes\tTaxes \t\tmunie.\tscol.Propriétaire»\t\tet int.\tet int.Cadastre\tLots\t\t Owners\t\tMunie.\tSchool \t\ttaxes\ttaxes \t\u2022\tand int.\tand int.Pelland, Paul-Emile.Par.de-of St-Norbert.Frechette, Micheline Gélinas.Par.de-of St-Norbert.\t143 & P.144.P.174 à-to P.179____ P.147.\ti 47.29\t$ 190.20 349.63 24.24 Municipalité de Lavaltrie (village) \u2014 Municipality of Lavaltrie (village) Giroux, Dame Marguerite D.Par.de-of Lavaltrie.80-8, 110 rue Ostiguy t 382.66 t 220.48 Giroux, Dame Marguerite D.Par.de-of Lavaltrie.59, 820-820A-822-824, 2,016.08 1,098.13 Notre-Dame.Morin, Marcel.Par.de-of Lavaltrie.58-9, rue Arcand.28.16 41.29 Morin, Marcel.Par.de-of Lavaltrie.68-8, 91.rue Arcand.468.04 253.29 Jette, André.Par.de-of Lavaltrie.58-10,58-P.11, 311.67 294.51 111 rue Arcand.Municipalité de Saint-Barthélémy \u2014 Municipality of Saint-Barthélémy Beaulieu, J.-Yvon.Par.Boudreau, Bernard.Par.Brizard, Oscar.Par.Carmel, Armand.Par.Giguère, Yvon.Par.Gravel, Armand.Par.Gravel, Pierre.Par.Jutras, Mme-Mrs.Clément (Bélisle).Par.Martin, Robert.Par.Pépin, Gérard.Par.St-Cyr, Louis.Par.Thibodeau, Sylva.Par.Trottier, Lionel.Par.Victor, Arthur.,.Par.de-of St-Barthélémy.de-of St-Barthélémy.de-of St-Barthélémy.de-of St-Barthélémy.de-of St-Barthélémy.de-of St-Barthélémy.de-of St-Barthélémy.de-of St-Barthélémy.de-of St-Barthélémy.de-of St-Barthélémy.de-of St-Barthélémy.de-of St-Barthélémy.de-of St-Barthélémv.de-of St-Barthélémy.1019P.$\t10.51 $\t43.33 1004P.\t64.03\t101.66 853P.\t\t4.26 836P.\t6.09\t43.96 598P.\t\t36.61 836P.\t37.55\t61.90 1ÔÏ9P.\t12.12\t67.35 651P.\t9.41\t30.56 798 P.\t4.12\t27.26 652P.\t48.64\t91.00 716P.\t4.12\t36.41 P.776, P.760, P.761.\t\t43.14 \t8.40\t45.39 980P.\t52.70\t240.20 Municipalité de L'Ile Saint-Ignace de Loyola \u2014 Municipality of L'Ile Saint-Ignace de Loyola Ethier, Jean-Paul.Par.de-of Visitation de-of 73P.l'Ile Dupas.Plante, Théodore.Par.de-of Visitation, de-of 86P.l'Ile Dupas.112.66 45.13 Municipalité de L'Ile Dupas \u2014 Municipality of L'Ile Dupas Lemire, Roland.Par.de-of Visitation de-of 344.S 11.98 l'Ile Dupas.Sylvestre, Annette, Eva & Ls.Victor.Par.de-of Visitation de-of 551.624.91 l'Ile Dupas.Donné à Berthierville, ce 6e jour de janvier 1972.Given at Berthierville, this 6th day of January, 1972.Le secrétaire-trésorier, J.-D.Giroux, 44027-3-2-o J.-D.Giroux.44027-3-2 Secretary-Treasurer. 800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n\" U Municipalité du conilé de Bellechasse Avis public est par les présentes donné par Maurille Bouchard, secrétaire-trésorier du Conseil du comté de Bellechasse, que les terrains ut-ou les bâtisses ci-après désignés, seront vendus à l'enchère publique, au lieu où le conseil tient ses séances, dans l'édifice du chef-lieu, à St-Raphaël, Bellechasse, JEUDI, le NEUVIÈME jour du mois de MARS, 1972, à DIX heures de l'avant-midi, pour taxes municipales, scolaires et les frais dus, à moins que ces diverses sommes et les frais encourus ne soient payés avant le jour indiqué, à savoir: Municipality of the County of BeUechasse Public notice is hereby given by Maurille Bouchard, Secretary-treasurer of the Council of the County of BeUechasse, that the lands and-or buildings hereinafter described will be sold by public auction at the place where the council holds its meetings, in the County Seat, at St.Raphaël, Bellechasse, on THURSDAY, the NINTH day of the month of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for municipal and school taxes and costs due, unless these various sums and costs incurred are paid before the date indicated, to wit: Municipalité de Saint-Cajetan d'Armagh \u2014 Municipality of Saint-Cajetan d'Armagh Taxes Taxes Nom No cadastre Rang munie.scolaires Frais Total Name Cadastre No.Range Mun.School Costs taxes taxes Succ.-Est.Joseph Morissette.%, 78.1 sud-est-south-east.S 17.77 $208.44 $226.21 Municipalité de N.-D.Auxiliatrice de Buckland \u2014 Municipality of N.-D.Auxiliatrice de Buckland Lamontagne, Adrien.2.3, 2 N.E., 5 N.E., 9 N.-O.-N.-W.$114.00 $325.61 $ 82.40 $521.91 P.56 O.-W.Municipalité de Saint-Magloire \u2014 Municipality of Saint-Magloire Comeau.Joseph.P.34.Roux N.E.$ 2.80 $ 0.86 $ 3.66 Municipalité de la paroisse de Saint-Vallier \u2014 Municipality of the parish of Saint-VaUier Côté, Raymond.P.166 18 du Couvent, Bienville Mercier, Simon.P.166 285 St-Joseph, Lauzon.Rochefort, André.170.Donné à St-Raphaël, Bellechasse, ce 6c jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44026-3-2-o Maurille Bouchard.Municipalité du comté de Charlevoix-Oucst Avis est par les présentes données, par le soussigné, Arthur Lavoie, secrétaire-trésorier du Conseil de comté de Charlevoix-Ouest, que JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi, au heu ou ledit conseil de comté tient ses assises au Palais de Justice de Baie-St-Paul, les immeubles suivants seront vendus à l'enchère publique à défaut de paiement de taxes municipales et scolaires et autres frais encourus sur l'iceux, à moins que le tout soit payé avant la vente, à savoir: $ 24.03 $ 24.03 21.18 21.18 8.00 8.00 Given at St.Raphaël, Bellechasse, this 6th day of January, 1972.Maurille Bouchard, 44026-3-2 Secretary-Treasurer.Municipality of the County of Charlcvoix-Wcst Notice is hereby given by the undersigned, Arthur Lavoie, Secretary-Treasurer of the Council of the County of Charlcvoix-West, that on THURSDAY, the NINTH day of MARCH 1972, at TEN o'clock in the forenoon, at the place where the said County Council holds its sittings in the Baie St.Paul Court House, the following immoveables will be sold by public auction, in default of payment of municipal and school taxes and other costs incurred thereon, unless the whole be paid before the sale, to wit: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 89, 1972, Vol.10i, No.I 801 Corporation municipale de la paroisse de Baie St-Paul Paul Bérubé, CP.94, St-Jean Port-Joli, comté de Kamouraska, P.Q.\u2014Taxes 1969-70-71: $12.60; frais à date: 82.07.Total: $14.67.Partie du lot 1403 au cadastre officiel de la paroisse de Baie St-Paul, Côte St-Gabriel, nécessaire à l'exploitation d'un moulin à scie, pour le terme de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 10 juillet 1920, avec droit de passage sur les lots 1396 et 1397 au cadastre officiel de Baie St-Paul pour communiquer au chemin public tel qu'établi selon les titres, avec les bâtises y érigées.Cette partie dudit lot mesure 300' x 400' mesure anglaise et est borné par M.Frs.Boivin et M.Chs-Eugène Boivin et par le résidu dudit lot 1403 en partie.Simon Bouchard, 37 Bas de la Baie, Baie St-Paul, Charlevoix.\u2014Taxes 1969-70-71.$42.04; frais à date: $2.07.Total: $46.11.Un emplacement de figure irréguliére et de contenance indéterminée, désigné comme étant les lots 1030, 1031 au cadastre officiel de la paroisse de la Baie St-Paul tel qu'enclos avec une maison d'habitation et dépan-dances dessus érigées.Avec un droit d'eau et le système d'aqueduc actuellement utilisé en commun avec d'autres usagers, mais dans la mesure seulement où le vendeur possède et jouit desdits droits et sans plus ample garantie de sa part.Corporation municipale Les Éboulements Armand Tremblay, Les Éboulements Village, Charlevoix.\u2014Taxes municipales 1968-69-70-71: 8210.00; taxes scolaire 1969-70-71-72- $154.69; frais à date: $2.07.Total: $366.76.Jean-Claudo Morin, adresse inconnue.\u2014 Taxes municipales 1968-69-70-71: S69.4S; taxes scolaires \u20ac968-69-70-71-72: $84.78; frais à date: $2.07.Total- $156.33.Mme François Beraier, 1525 rue Caton, Ottawa, Ontario, Canada.\u2014Taxes scolaires 1969-70-71-72 $55.07; frais à date: $2.07.Total: $57.14.Donné à Baie St-Paul, ce 6e jour de janvier 1972 Le secrétaire trésorier 44028-3-2-o Arthur Lavoie.Municipal Corporation of the Parish of Baie St-Paul Paul Bérubé, P.O.Box 94, St-Jean Port-Joli, County of Kamouraska P.Q.\u2014Taxes 1969-70-71: $12.60; costs to date: $2.07.Total: $14.67.Part of lot 1403 of the official cadastre of the Parish of Baie St.Paul, Côte St-Gabriel, used for the operation of a saw mill for a term of ninety-nine years upon, from and after the Julv 10, 1920, with a right of way on lots 1396 and 1397 of the official cadastre of Baie St.Paul to communicate with the public road, as established according to titles, with buildings erected thereon.This part of the said lot measures 300' x 400', English measure, and is bounded by Mr.Fis.Boivin and Mr.Chs-Eugène Boivin and by the remainder of said lot 1403 in part.Simon Bouchard, 37 Bas de la Baie, Baie St-Paul, Charlevoix.\u2014Taxes: 1969-70-71: $42.04; costs to date: $2.07.Total: $46.11.An emplacement of an irregular configuration and of an undertermined area, described as being lots 1030, 1031 of the official cadastre of the Parish of Baie St.Paul as enclosed with a house and dependencies erected thereon.With water, rights and the aqueduct system now used in common with other users, but only if the vendor owns and profits by the said rights, without greater guarantee on his part.Municipal Corporation of Les Éboulements Armand Tremblay, Les Éboulements Village, Charlevoix.\u2014Municipal taxes: 1968-69-70-71: $210.00; School taxes 1969-70-71-72: $154.69; costs to date: $2.07.Total: $366.76.Jean-Claude Morin, unknown address.\u2014 Municipal taxes 1968-69-70-71: $69.48; School taxes 1968-69-70-71-72: $84.78; costs to date: $2.07.Total: $156.33.Mrs.François Bernier, 1025 Caton Street, Ottawa, Ontario, Canada.\u2014 School taxes 1969-70-71-72: $55.07; costs to date: $2.07.Total: $57.14.Given at Baie St.Paul, this 6th day of January, 1972.Arthur Lavoie, 44028-3-2 Secretary-Treasurer.Municipalité du comté de Terrebonne Avis public est par les présentes donné par le soussigné, André Tassé, secrétaire-trésorier, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l'enchère publique, (selon la loi) au lieu où le conseil tient ses séances, au Palais de Justice de St-Jérôme, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi, pour défaut de paiement des taxes municipales et scolaires ou autres impositions dues sur ces immeubles, si ces taxes ne sont pas payées, avec les frais encourus, avant le jour fixé pour la vente.Municipality of the County of Terrebonne Public notice is hereby given by the undersigned, André Tassé, Secretary-Treasurer, that the immoveables hereinafter described will be sold by public auction, (according to law), at the place where the Council holds its meetings, in the St.Jérôme Court House, on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for default of payment of municipal and school taxes and other taxes due on these immoveables, if these taxes are not paid, with costs incurred, before the date fixed for the sale. 802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101' année, n° A Municipalité de la paroisse de Saint-Louis de Terrebonne Municipality of the parish of Saint-Louis de Terrebonne Taxes Taxes Taxes scol.scol.Noms Lots et cad.munie.cath.prot.lotal Names Lots and cad.Munie.Cath.Prot.taxes school school taxes taxes Aubin, Monique.282-18.283-10.Barr, Richard.1.637-19.Beaulieu, Thérèse Cloutier.P.131.Un emplacement situé en la paroisse St-Louis de Terrebonne, a distraire du lot originaire no 131 des plans et livres de renvoi officiels du cadastre de ladite paroisse mesurant cinquante pieds de largeur en front le long de la Montée Pin-court par une profondeur de 90 pieds, mesure anglaise plus ou moins et borné en front par ladite avenue Montée Pincourt, (un côté au nord par l'emplacement de M.Gabriel Lamoureux ou représentants de l'autre côté au nord par le terrain appartenant à M.René Beauchesne ou représentants en arrière par une autre partie du lot originaire no 131 appartenant à M.Roland Martin ou représentants.Benoit.Claude.P.271.Un emplacement mesurant 90 pieds de largeur sur une profondeur de 81 pieds le tout de mesure anglaise, plus ou moins, en front à l'ouest par la rue Lamothe, au sud par d'autres parties du lot no 271 dudit cadastre appartenant à M.Gonzague Lamothe ou représentants, à l'est par l'emplacement appartenant à M.Jean-Paul Lachapelle ou représentants et au nord par l'emplacement appartenant à M.Alfred Demers ou représentants.Avec un camp d'été dessus érigé.634-39.534-40.534-41.534-42.Bergeron, André, a/s-c/o Gérard Lavoie 537-31.Biais, Gérald.2S2-14, 283-6.Entreprises Gerbex.535-12.Montréal Jet Poot.537-79.Ladouceur, Lucien.283-38.Cloutier, Jacques.46-52.Cloutier, Jacques.46-73.Harvev, Louisa Maria Bédard.347-21.Hurtubise.J.R.634-30.Hurtubise, J.R.534-31.Hurtubise, J.R.534-32.Hurtubise, J.R.534-36.Hurtubise, J.R.634-37.Hurtubise, J.R.534-38.Hurtubise, J.R.Hurtubise, J.R.Hurtubise, J.R.Hurtubise, J.R.Hurtubise, J.R.534-43.Hurtubise.J.R.634-44.Hurtubise, J.R.Hurtubise, J.R.Hurtubise, J.R.Hurtubise, J.R.Hurtubise, J.R.Hurtubise, J.R.Hurtubise, J.R.Hurtubise, J.R.634-55.Lamothe, Jean.P.271.Un emplacement mesurant 135 pieds de largeur par SI pieds de profondeur mesure anglaise plus ou moins avec toutes bâtisses dessus érigées borné en front à l'ouest par la rue Lamothe.de chaque côté au nord et au sud par d'autres parties du lot 271 appartenant à M.Gonzague Lamothe ou représentants, en arrière à l'est par une partie du lot 268 appartenant à M.Lucien Archambault ou repié=entants.La ligne frontale du susdit emplacement à son intersection avec; la ligne nord est situé à 142 pieds du chemin St-Hoch et que la ligne arrière ù son intersection avec la ligne nord est situé ù 83 pieds du Chemin St-Roch.534-45.534-46.634^7.634-49.534-60.534-51.534-52.$ 106.05 $ 28.50 $ 134.65 .83.01 183.41 266.42 .86.98 378.52 465.50 An emplacement situated in the Parish of St.Louis de Terrebonne, save and to withdraw from original lot No.131 in the official plan and book of reference of the cadastre of the said parish measuring fifty feet in width in front along Montée Pincourt by a depth of 90 feet, English measure, more or less, and bounded in front by the said Montée Pincourt Avenue, (on one side on the north by the emplacement of Mr.Gabriel Lamoureux or representatives, on the other side on the north by the land belonging to Mr.René Beauchesne or representatives, in the rear by another part of original lot No.131 belonging to Mr.Roland Martin or representatives.136.36 120.68 256.04 An emplacement measuring 90 feet in width by a depth of 81 feet, the whole English measure, more or less, in front on the west by Lamothe Street, on the south by other parts of lot No.271 of the said cadastre belonging to Mr.Gonzague Lamothe or representatives, on the east by the emplacement belonging to Mr.Jean-Paul Lachapelle or representatives and on the north by the emplacement belonging ot Mr.Alfred Demers or representatives.With a summer camp erected thereon.192.94 393.18 586.12 .159.34 32.30 191.64 .148.03 506.53 654.56 .120.65 205.86 326.61 .271.75 1,024.21 1,295.96 .124.18 774.43 898.61 .15.29 43.86 59.15 .20.11 36.85 56.96 .\u2022 11.30 31.00 42.30 .9.55 24.76 34.31 .9.55 24.76 34.31 .9.65 24.76 34.31 .9.65 24.76 34.31 .9.55 24.76 34.31 .9.55 24.76 34.31 .9.65 24.76 34.31 .10.10 26.60 36.60 .10.40 27.67 38.07 .9.65 24.76 34.31 .9.65 24.76 34.31 .9.66 24.76 34.31 .9.55 24.76 34.31 .9.66 24.76 34.31 .5.60 11.49 17.09 .9.55 24.76 34.31 .9.66 24.76 34.31 .9.56 24.76 34.31 .9.69 24.76 34.45 .189.88 234.82 424.70 An emplacement measuring 136 feet in width by 81 feet in depth, English measure, more or less, with any and all buildings erected thereon, bounded in front on the west by Lamothe Street, on each side on the north and south by oher parts of lot 271 belonging to Mr.Gonzague Lamothe or representatives, in the rear on the east by a part of lot 268 belonging to Mr.Lucien Archambault or representatives.The frontal line of the aforesaid emplacement at its intersection with; the north Une is situated 142 feet from St-Roch Road and the rear line at its intersection with the north line is situated 83 feet from St-Roch Road. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10L, No. 803 \t\t\tTaxe»\tTaxes \t\tTaxes\t8COl.\tscol.Noma\tLots et cad.\tmunie.\tcath.\tprot.Names\tLots and ead.\tMunie.\tCath.\tProt.\t\ttaxes\tschool\tschool \t\t\ttaxes\ttaxes Total Landry.Clermont.654-3.Larochelle, Yvon.282-19.283-11.Lauzon, Irène Boisvert.642, 543.Les Res.Fam.St-Louis Inc.637-66.Les Rés.Fam.St-Louis Inc.637-62.Les Rés.Fam.St-Louis Ine.537-64.Les Rés.Fam.St-Louis Inc.637-65.Les Rés.Fam.St-Louis Ine.637-66.Les Rés.Fam.St-Louis Inc.537-68.Les Rés.Fam.St-Louis Inc.537-69.Leo Réo.Fam.St-Louis Inc.637-70.Les Rés.Fam.St-Louis Inc.537-71.Les Terres Laurentiennes Inc.537-42.St-Onge, Fernand.131-19.\".Sansfaçon, Gilles.537-25.Smith, Bernard J.P.119.Un emplacement en la paroisse St-Louis de Terrebonne, à distraire du lot originaire no 119 des plans et livres de renvoi officiels du cadastre de ladite paroisse située à une distance de 352 pieds du chemin public et mesurant 193 pieds de largeur par une profondeur dans la ligne ouest de 176 pieds et 5/10 de pieds, au sud-est une distance de 91 pieds et 6/10 de pieds, au sud une distance de 32 pieds 4/10 de pieds et ce point à l'est une distance de 107 pieds et 3/10 de pieds et de ce point au nord une distance de 237 pieds étant la ligne est et de ce point au commencement.$ 27.13 107.14 1.28 18.62 16.68 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.42 135.94 62.61 189.01 66.45 S 29.63 30.97 2.81 37.12 33.08 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 413.91 1.54 350.08 163.35 S 405.13 f 66.66 138.11 4.09 55.74 49.66 42.98 42.98 42.98 42.98 42.98 42.98 43.04 549.85 64.16 539.09 634.93 An emplacement in the Parish of St.Louis de Terrebonne, save and to withdraw from original lot No.119 in the official plan and book of reference of the cadastre of the said parish situated 362 feet from the public road and measuring 193 feet in width by a depth on the west line of 176 and 5/10 feet, on the southeast 91 and 6/10 feet, on the south 32 and 4/10 feet and this point on the east 107 and 3/10 feet and from this point on the north 237 feet being the east line and from this point to the starting point.Entreprises Gerbex.637-15.192.22 341.01 633.23 Municipalité du village de Bois des Filion Municipality of the village of Bois des Filion Taxes Taxes Noma Lots et cad.Rang munie.scol.Total Names Lots and cad.Range Munie.School taxes taxes Monnar, Joseph.11-116(1).S 398.98 $ 73.36 S 472.34 Chaput, succ.-est.Wilfrid.P.13 (2).255.86 115.01 370.87 Borné au nord: limite municipale, 6ud: lot 11, est: lot 14, Bounded on north: Municipal limits, south: lot 11, east: ouest: lot 12.lot 14, west: lot 12.Fortin, Fernando.P.16 (2).363.54 180.62 644.16 Borné au nord: limite municipale, sud: lot 14, est: lot 17, Bounded on north: Municipal limits, Bouth: lot 14, east: ouest : lot 14.lot 17, west:lot 14.Rami Construction.P.23 (2).247.63 79.05 326.68 Borné au nord: partie du lot 23, sud: route 29, est : partie du Bounded on north: part of lot 23, south: road 29, east: lot 23 (M.A.Ouimet), ouest: partie du lot 23 (M.Guy Beau- part of lot 23 (M.A.Ouimet), west: part of lot 23 (M.Guy chemin).Beauchemin).Lacelles, succ.-est.Emilien.11-124 (1).745.78 248.36 994.14 N.B.Le no (11 indique le cadnstre de la paroisse de Ste- N.B.No.(1) indicates the cadastre of the Parish of St.Thérèse de Blainville.Thérèse de Blainville.Le no (2) indique le cadastre de la paroisse de St-Louis de No.(2) indicates the cadastre of the Parish of St.Louis de Terrebonne.Terrebonne. 804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 La municipalité scolaire protestante de Laurenvale The Protestant school municipality of Laurenvale Noms Names Lots et cad.Lots and cad.Taxea munie.Munie, taxes Taxes ecol.cath.Cath.school taxea Taxes scol.prot.Prot.school taxes Total Rousse.Gilles.38.* 89.95 t 39.95 Rousse, Gilles.39.175 39 175.39 Les lots ci-dessus font partie du cadastre officiel de la ville The abovementioned are part of the official cadastre of the de terrebonne.Town of Terrebonne.Biais, Maurice.209-16.405.02 405.02 De Sevc.Roger.231-12 .559.02 559.02 Benroar Dev.Corp.667-1,107-1.107-2,107-3,107-1 $81,619.50 3.821.76 85.341.26 Les lots ci-dessus font partie du cadastre officiel du village de The lots hereabove are part of the official cadastre of the Sainte-Thérèse.Village of St.Thérèse.Thompson, Roddy.277-P-45.219.18 219.18 Bornés: N.E.avenue Fraser, S.E.P.277-45.S.O.P.277, Bounded: N.E.Fraser Avenue, S.E.P.277-45, S.W.P.277, N.O.277-44, superficie: 5.000p.c.N.W.277-44, area: 5.000 sq.ft.Les lots ci-dessus fait partie du cadastre officiel de la pa- The abovementioned are part of the official cadastre of the roisse de Ste-Thérèse de Blainville.Parish of St.Thérèse de Blainville.Anderson, E.35-60-1.114.89 114.89 Anderson.E.35-61-1.668.14 668.14 Butler, Anthony E.65-89.139.80 139.80 CoUyer.James.36-121.1,876.16 1,876.16 Dawson.Mme-Mrs.Wm.253-21,253-22.1,104.87 1,104.87 Makin.Thomas O.C.66-37.1,163.37 1,163.37 Nikitin, John.27-30,27-31.382.32 382.32 Norris, Mme-Mrs.A.P.40-67.1,664.63 1,664.63 Bornes: N.E.avenue Cedar, S.O.boulevard Rosemère, Bounded: N.E.Cedar Avenue, S.W.Rosemère Boulevard, N.O.P.40, S.E.40-68, superficie: 39,142 p.c.N.W.P.40, S.E.40-68, area: 39,142 sq.ft.Orr, Norman.62-71.169.45 169.45 Oppenheimer, Peter V.30-64.732.46 732.46 Poirier.M.-Mr.J.Paul.15-7,15-6.70.74 70.74 Tessier, C.& Polini, L.260-10 .357.97 585.52 943.49 Vary.M.-Mr.F.928-55-2.928-56,928-57-1.877.41 292.02 1,169.43 Jullmark Corp.66-54 .41.67 32.81 74.48 JullmarkCorp.P.66.1,655.47 1,185.77 2,841.24 Bornes: N.E.P.65, S.E.66-50, N.E.66-48, S.O.11, P.66, Bounded: N.E.P.65, S.E.66-50, N.E.66-48, S.W.71, P.66, superficie: 37.02 arp.area 37.02 arpents.JullmarkCorp.66-55.Jullmark Corp.66-58.JullmarkCorp.68-60.JullmarkCorp.66-61.JullmarkCorp.66-62.Jullmark Corp.66-68.Reggio Construction.66-59.Rcggio Construction.66-66 & 66-65-1.Reggio Construction.66-67.Northcote Inv.Corp.\u2022.P.18.Bornes: N.E.17.S.O.19.N O.326-328, S.E.18-1, super- Bounded: N.E.17.S.W.19, N.W.326-328, S.E.18-1, area: ficie: 54.86arp.64.86 arpents.Axminister Hlds.& Inv.Ltd.P.19 .620.93 369.31 990.24 Bornes: S.E.10-6.S.O.19, N.E.18, N.O.20, superficie Bounded: S.E.19-6.S.W.19, N.E.18, N.W.20, area: 16.45 16.45 arp.arpents.Rosa, M.-Mr.R.35-65-2,35-66-1.122.24 122.24 Beer, Marc S.176-125.8.10 32.53 40.63 Beer, Marc S.176-126.8.10 32.63 40.63 Beer, Marc S.175-127.10.29 38.09 48.38 Beer, Marc S.175-124.8.10 32.53 40.63 Green, Mme-Mrs.Eva.158-164.12.21 36.90 49 11 Green, Mme-Mrs.Eva.158-166.11.69 35.39 46.98 Green, Mme-Mrs.Eva.168-167.11.69 35.39 46.98 Green, Mme-Mrs.Eva.158-168.11.69 35.39 48.98 41.67\t32.81\t74.48 39.44\t31.30\t70.74 39.44\t31.30\t70.74 28.98\t15.48\t44.46 28.98\t15.48\t44.46 40.19\t28.71\t68.90 65.42\t37.65\t102.97 72.65\t41.27\t113.83 67.20\t33.31\t90.61 2,368.07\t1,119.11\t3,487.16 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972.Vol 101, No.4 805 Taxes Taxes Taxes scol.scol.Noma Lots et cad.munie.cath.prot.Total Names Lots and cad.Munie.Cath.Prot.taxes school school taxes taxea \t.158-169.,____\t.( 11\t.69\t\t$ 36\t.39\t8 46.98 \t.168-170.\t____ 11\t69\t\t35\t.39\t46.98 \t\t\t69\t\t35\t14\t46.73 \t.158-172.\t12\t05\t\t66\t09\t67.14 \t.175-334.\t4.\t17\t\t25\t86\t30.03 \t.175-335.\t____ 4\t.02\t\t25\t02\t29.04 \t\t\t.02\t\t25\t.05\t29.07 \t.175-337.\t4\t.02\t\t25\t.06\t29.07 Green, Mme-Mrs.Eva.\t.175-338.\t____ 4\t.02\t\t25\t.06\t29.07 \t\t4\t.02\t\t25\t.05\t29.07 \t.175-340.\t____ 4\t.02\t\t25\t.05\t29.07 \t.175-341.\t4\t.02\t\t20\t00\t29.07 \t\t____ 4\t.02\t\t25\t00\t29.02 \t.175-343.\t4\t.02\t\t25\t00\t29.02 \t.175-344.\t____ 4\t.02\t\tIS\t.11\t22.13 \t.175-345.\t4\t02\t\t18\t.11\t22.13 \t.175-346.\t4.\till\t\t21\t68\t26.52 \t.175-347.\t6\t.10\t\t22\t15\t27.25 \t.176-356.\t4\t64\t\t20\t42\t25.06 \t.175-357.\t4.\t64\t\t20.\t42\t25.06 \t.175-362.\t4.\t64\t\t20\t42\t25.06 \t.175-363.\t____ 4\t64\t\t20\t.42\t25.06 \t.101-88, 102-59.\t666\t.15\tS 88.16\t1,118\t.56\t1,762.87 \t.187-20.\t\t\t\t128\t.67\t128.67 \t.187-21.\t\t\t\t99\t01\t99.01 \t.187-26.\t\t\t\t47.\t98\t47.98 \t\t\t\t\t47.\t10\t47.10 \t.742-262.\t\t\t\t40\t(18\t40.98 \t.440.\t\t\t976.75\t800\t94\t1,777.69 Les lots ci-dessus font partie du cadastre officiel de la pa- The abovementioned lots are part of the official cadastre of roisse de Ste-Thérèse de Blainville.the Parish of St.Thérèse de Blainville.Commission scolaire de la ville de Sainte-Thérèse Town of 8ainte-Thérèse School Board Pimentel, José.61 P.69.Un emplacement connu et désigné comme étant une partie du lot soixante-neuf de la subdivision officielle du lot originaire no soixante et un (61-P.69), mesurant quarante-trois pieds (43') de largeur par cent pieds (100') de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins et borné comme suit: en front vers l'est par la rue Lonergan, en arrière vers l'ouest et d'un côté vers le sud par des parties du lot 61-69 appartenant à Roger Forget, de l'autre côté vers le nord, par le lot 61-77 du même cadastre.B) Un emplacement connu et désigné comme étant une partie du lot numéro soixante-neuf de la subdivision officielle du lot originaire no soixante et un (61-P.69), mesurant quarante-trois pieds (43') de largeur dans la ligne est.cinquante pieds (50') de profondeur dans la ligne nord, trente-deux pieds (32') dans la ligne sud, vingt-trois pieds (23') dans la ligne sud-ouest, vingt-six pieds (26') dans la ligne ouest et borné comme suit : en front vers l'est par une partie du lot 61-69 appartenant à José Pimentel ou représentants, en arrière vers l'ouest par une partie du lot 61-75 appartenant à Jacques Sicotte ou représentants, d'un côté vers !e nord par une partie du lot 61-76 appartenant à Claude Beaulne, de l'autre côté vers le sud par une partie du lot 61-69 appartenant à Roger Forget ou représentants, vers le sud-ouest par une partie du lot 67 du même cadastre.8 350.63 8 718.21 S 1,068.84 (a) An emplacement known and designated as being a part of lot sixty-nine of the official subdivision of original lot number sixty-one (61-P.69), measuring forty-three feet (43') in width by one hundred feet (100') in depth, English measure, more or less and bounded as follows: in front on the east by Lonergan Street, in the rear on the west and on one side on the south by parts of lot 61-69 belonging to Roger Forget, on the other side on the north by lot 61-77 of the same cadastre.(6) An emplacement known and designated as being a part of lot number sixty-nine of the official subdivision of original lot number sixty-one (61-P.69), measuring forty-three feet (43') in width on the east line, fifty feet (50') in depth on the north line, thirty-two feet (32') on the south line, twenty-three feet (23') on the southwest line, twenty-six feet (26') on the west line and bounded as follows : in front on the east by a part of lot 61-99 belonging to José Pimentel or representatives, in the rear on the west by a part of lot 61-75 belonging to Jacques Sicotte or representatives, on one side on the north by a part of lot 61-76 belonging to Claude Beaulne, on the other side on the south by a part of lot 61-69 belonging to Roger Forget or representatives, on the southwest by a part of lot 67 of the same cadastre.V Lachance, Fernand.67-179 .2,019.46 2,445.75 Lachance,Mme-Mrs.Madeleine Boutin.67-180.1,853.34 2,426.55 Lachance, Mme-Mrs.Madeleine Boutin.67-181.926.63 171.08 Les Entreprises Blanchard 4 Kunzli Ltée 226-22,227-37.712.40 1,480.99 Les Développements Domiciliaires T.tée.223-33, 226-30 .241 30 961.64 8 68.46 4,465.21 4,279.89 1,097.71 2,261.85 1.202.94 806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Taxes Taxes Taxes scol.scol.Noms Lots et cad.munie, cath.prot.Total Names Lots and cad.Munie.Cath.Prot.taxes school school taxes taxes Prosperity Dev.Corp.P.81-34, P.81-33.A) Un emplacement de forme triangulaire, situé en la ville .de Ste-Thérèse ouest.connu et désigné comme étant une partie du lot numéro trente-trois de la subdivision officielle du lot originaire no quatre vingt-un (Sl-P.33), mesurant dans la ligne nord vingt-sept pieds et vingt-huit centièmes de pied (27.28'), dans la ligne sud-est vingt-trois pieds et soixante trois centièmes de pied (23.63'), dans la ligne sud-ouest quatorze pieds et soixante et un centièmes de pied (14.61'); contenant en superficie cent soixante-treize pieds carrés (173 pi.ca.) mesure anglaise, plus ou moins, et borné comme suit: ver* le nord par le résidu du lot 81-33 appartenant au Ministère de la Voirie, vers le sud-est par le lot 81-36 et vers le sud-ouest par le lot 81-34.B) Un emplacement de forme irrégulière, situé en la ville de Ste-Thérèse ouest, connu et désigné comme étant une partie du lot no trente-quatre de la subdivision officielle du lot originaire no quatre vingt-un (81-P.34), mesurant quatre-vingt-sept pieds et trente-neuf centièmes de pied (87.39') dans la ligne nord, quatre-vingt-six pieds et quatre dixièmes de pied (86.4') dans la ligne sud-est, soixante pied* et cinquante-neuf centièmes de pied (60.59') dans la ligne sud-ouest, douze pieds et quinze centièmes de pied (12.15') dans la ligne nord-ouest, quatorze pieds et soixante et un centièmes de pied (14.61') dans la ligne nord-est; contenant en superficie trois mille cinq cent dix-sept pieds carrés (3,517 pi.ca.) mesure anglaise, plus ou moins, et borné comme suit: vers le nord par le résidu du lot 81-34, vers le sud-est par le lot 81-35, vers le sud-ouest par une partie du lot 84.Prosperity Dev.Corp.P.81-36, P.81-35.Un emplacement de forme irrégulière, situé en la ville de Ste-Thérèse ouest, connu et désigné comme étant une partie du lot no trente-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre-vingt-un (81-P.36), mesurant soixante-treize pieds et trente-huit centièmes de pied (73.38'ï dans la ligne nord, quatre-vingt-cinq pieds et soixante centièmes de pied (85.60') dans la ligne sud-est, soixante pieds et cinquante-neuf centièmes de pied (60.59') dans la ligne sud-ouest; contenant en superficie trois mille neuf cent quatre-vingt-seize pieds carrés (3,996 pi.ca.) mesure anglaise, plus ou moins et borné comme suit: vers le nord par le résidu du lot 81-36, vers le sud-est par le lot 81-37, vers le sud-ouest par le lot 81-35.Prosperity Dev.Corp.81-37, 81-38.Prosperity Dev.Corp.81-40, 81-39.Prosperity Dev.Corp.81-41, 81-42.Prosperity Dev.Corp.81-43, 81-44.Prosperity Dev.Corp.81-45,81-46.Prosperity Dev.Corp.81-47,81-48.Prosperity Dev.Corp.81-49,81-50.Gravel, Roland.P.646.Un terrain vacant ayant front sur la 37e Avenue, via boulevard Labelle, en la ville de Blainville, connu et désigné comme faisant partie du lot numéro cinq cent quarante-cinq (P.545), mesurant quatre-vingt-deux (82') de largeur sur soixante pieds (60') de profondeur, le tout de mesure anglaise, plus ou moins et borné comme suit: en front, vers le sud-ouest par la 37e Avenue, en arrière vers le nord-ouest par partie dudit lot no 545, du même cadastre, appartenant a, Gaston Vézina, d'un côté vers le nord-est par partie dudit lot no 545, du même cadastre, appartenant à André Gravel et de l'autre côté vers le sud-ouest par partie dudit lot no 545, du même cadastre appartenant a Jean-Claude Tétreault.Ferraro, Dominico.P.546.Un emplacement faisant partie du lot no cinq cent quarante-cinq (P.545), mesurant cent dix-huit pieds (118') de largeur par cent vingt pieds (120') de profondeur, mesures .8 38.08 8 1.72 8 39.80 (a) An emplacement of a triangular configuration situated in the Town of St.Thérèse West, known and designated as being a part of lot number thirty-three of the official subdivision of original lot number eighty-one (81-P.33), measuring on the north line, twenty-seven and twenty-eight hundredths feet (27.28'), on the southeast line twenty-three and sixty-three hundredths feet (23.63'), on the southwest line fourteen and sixty-one hundredths feet (14.61'); containing in area one hundred and seventy-three square feet (173 sq.ft.), English measure, more or less, and bounded as follows: on the north by the remainder of lot 81-33 belonging to the Department of Roads, on the southeast by lot 81-36 and on the southwest by lot 81-34.(6) An emplacement of an irregular configuration situated in the Town of St.Thérèse West, known and designated as being a part of lot number thirty-four of the official subdivision of original lot number eighty-one (81-P.34), measuring eighty-seven and thirty-nine hundredths feet (87.39') on the north line, eighty-six and four tenths feet (86.4') on the southeast line, sixty and fifty-nine hundredths feet (60.59') on the southwest line, twelve and fifteen hundredths feet (12.15') on the northwest line, fourteen and sixty-one hundredths feet (14.61') on the northeast line, containing three thousand five hundred and seventeen square feet (3,517 sq.ft.), English measure, more or less, and bounded as follows: on the north by the remainder of lot 81-34, on the southeast by lot 81-35, on the southwest by a part of lot 84.' 46.77 3.33 60.10 An emplacement of an irregular configuration situated in the Town of St.Thérèse West, known and designated as being a part of lot number thirty-six of the official subdivision of original lot number eighty-one (81-P.36), measuring seventy-three and thirty-eight hundredths feet (73.38') on the north line, eighty-five and sixty hundredths feet (86.60') on the southeast line, sixty and fifty-nine hundredths feet (60.59') on tho southwest line; containing in area three thousand nine hundred and ninety-six square feet (3,996 sq.ft.), English measure, more or less and bounded as follows: on the north by the remainder of lot 81-36, on the southeast by lot 81-37, on the southwest by lot 81-35.37.48 37.48 37.48 37.11 37.11 37.10 36.78 S 333.88 8 66.60 3.40 40.88 3.40 40.88 3.40 40.88 3.38 40.49 3.38 40.49 3.38 40.48 3.33 40.11 $ 400.38 A vacant piece of land fronting on 37th Avenue, via Labelle Boulevard, in the Town of Blainville, known and designated as forming part of lot number five hundred and forty-five (P.545), measuring eighty-two feet (82') in width by sixty feet (60') in depth, the whole English measure, more or less, and bounded as follows: in front, on the southwest by 37th Avenue, in the rear on the northwest by part of said lot No.545 of the same cadastre belonging to Gaston Vézina, on one side on the northeast by part of said lot No.545 of the same cadastre belonging to André Gravel and on the other side on the southwest by part of said lot No.646 of the same cadastre belonging to Jean-Claude Tétreault.89.92 89.92 An emplacement forming part of lot number five hundred and forty-five (P.645), measuring one hundred and eighteen feet (118') in width by one hundred and twenty feet (130') QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.I 807 anglaises, plus ou moins, et borné comme suit: en front vers le sud par la rue Lemieux, en arrière vers le nord par la propriété de Charles Leblanc ou représentants, d'un côté vers l'est par une autre propriété de Ferraro Dominico, de l'autre côté vers l'ouest par la propriété de Joseph Palick ou représentants.in depth, English measure, more or less, and bounded as follows: in front on the south by Lemieux Street, in the rear on the north by the property of Charles Leblanc or representatives, on one side on the east by another property of Ferraro Dominico, on the other side on the west by the property of Joseph Palick or representatives.Taxes Taxes Taxes scol.scol.Noms Lots et cad.munie.cath.prot.Total Names Lots and cad.Munie.Cath.Prot.taxes school school taxes taxes Demeule, Robert.743-84.Farias, José.P.784.Un emplacement ayant front sur la 81e Avenue connu et désigné comme faisant partie du lot numéro sept cent quatre-vingt-quatre (P.784), mesurant quatre-vingt-dix pieds (90') de largeur par soixante-quinze pieds (75') de profondeur, mesures anglaises plus ou moins et borné comme suit: en front vers le sud-est par la 81e Avenue, en arrière vers le nord-ouest par une partie du lot 784 appartenant à Edwin A.Marks ou représentants, d'un côté vers le nord-est par une partie du lot 784 appartenant à Eugène Turcot ou représentants, de l'autre côté vers le sud-ouest par le lot 784-1 appartenant à Eugène Turcot ou représentants.Posd Investment Inc.766-65.Bougie, Mme-Mrs.Marguerite Hanck.P.531.Un emplacement faisant partie du lot numéro cinq cent.trente un un (P.531), mesurant soixante pieds (60') le long de la route no 11 ou boulevard Labelle par deux cent soixante-dix pieds (270') perpendiculairement à la route no 11 et borné comme suit: en front vers l'ouest par la route 11, en arrière, vers l'est par le résidu du lot 531, d'un côté vers le nord par une partie du lot 531 appartenant à Gaston Dumoulin ou représentants, de l'autre côté vers le sud par l'emplacement de J.B.Lamothe ou représentants.Ayotte, Jean-Guy.P.785.Un emplacement faisant partie du lot no sept cent quatre-vingt-cinq (P.785) mesurant soixante-quatorze pieds (74') de l'argeur par soixante-quinze pieds (75') de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins et borné comme suit: en front vers l'ouest par le boulevard Labelle, en arrière vers l'est par partie du lot 785 appartenant à Eugène Turcot ou représentants, d'un côté vers le nord par une partie du lot 785-1, de l'autre côté vers le sud par une partie du lot 785 appartenant à Agénor Maheu ou représentants.Perreault, Narcisse.P.543.Un emplacement faisant partie du lot numéro cinq cent quarante-trois (P.543), mesurant cinquante pieds (50') de largeur, mesure anglaise, le long de la route no 11 par deux (2) arpents de profondeur, plus ou moins et borné comme suit: vers le nord par une partie du lot 543 appartenant à C.Mar-leau ou représentants, vers le sud par une partie du lot 543 appartenant à C.Charron ou représentants, vers l'est par la route no 11, vers l'ouest par le terrain de Ernest Paquin ou représentants.A distraire dudit emplacement la partie expropriée par le Gouvernement du Québec pour l'élargissement de la route no 11.Houle, Mme-Mrs.Pierrette Leblanc.P.545.Un emplacement faisant partie du lot numéro cinq cent quarante-cinq (P.545), mesurant soixante-quinze pieds (75') de largeur par mille quatre-vingts pieds (1,080') de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins et borné comme suit: en front vers l'est par le boulevard Labelle, en arrière vers l'ouest par une partie du lot 546, d'un côté vers le nord par une partie du lot 545 appartenant à William Lavallée ou représentants et de l'autre côté vers le sud par le terrain appartenant à Léo Laperrière ou représentante.$ 352.20 $ 414.59 $ 766.79 .178.94 316.71 495.65 An emplacement fronting on Slot Avenue known and designated as forming part of lot number seven hundred and eighty-four (P.784), measuring ninety feet (90') in width by seventy-five feet (75') in depth, English measure, more or less and bounded as follows: in front on the southeast by 81st Avenue, in the rear on the northwest by a part of lot 784 belonging to Edwin A.Marks or representatives, on one side on the northeast by a part of lot 784 belonging to Eugène Turcot or representatives, on the other side on the southwest by lot 784-1 belonging to Eugène Turcot or representatives.236.54 201.54 438.08 .265.99 409.90 675.89 An emplacement forming part of lot number five hundred and thirty-one (P.531), measuring sixty feet (60') along Highway No.11 or Labelle Boulevard by two hundred and seventy feet (270') at right angles to Highway No.11 and bounded as follows: in front on the west by Highway 11, in the rear on the east by the remainder of lot 531, on one side on the north by a part of lot 531 belonging to Gaston Dumoulin or representatives, on the other side on the south by the emplacement of J.B.Lamothe or representatives.254.36 1,047.81 1,302.17 An emplacement forming part of lot number seven hundred and eighty-five (P.785) measuring seventy-four feet (74') in width by seventy-five feet (75') in depth, English measure, more or less and bounded as follows: in front on the west by Labelle Boulevard, in the rear on the east by part of lot 785 belonging to Eugène Turcot or representatives, on one side on the north by a part of lot 785-1, on the other side on the south by a part of lot 785 belonging to Agénor Maheu or representatives.236.71 335.69 572.40 An emplacement forming part of lot number five hundred and forty-three (P.543) measuring fifty feet (50') in width, English measure, along Highway No.11 by two (2) arpents in depth, more or less and bounded as follows: on the north by a part of lot 543 belonging to C.Marleau or representatives, on the south by a part of lot 543 belonging to C.Charron or representatives, on the east by Highway No.11, on the west by the land of Ernest Paquin or representatives.Save and to withdraw from the said emplacement, the part expropriated by the Québec Government for the enlargement of Highway No.11.632.76 329.16 861.92 An emplacement forming part of lot number five hundred and forty-five (P.545), measuring seventy-five feet (75') in width by one thousand eighty feet (1,080') in depth, English measure, more or less and bounded as follows: in front on the east by Labelle Boulevard, in the rear on the west by a part of lot 546, on one side on the north by a part of lot 545 belonging to William Lavallée or representatives and on the other side on the south by the land belonging to Léo Laperrière or representatives. 808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S9 janvier 1972, 101' année, n° k Taxea Taxée Taxes scol.scol.Noms Lots et cad.munie.cath.prot.Names Lota and cad.Munie.Cath.Prot.taxes school school Total taxes taxes Jutras, Bertrand.P.770.A) Un emplacement faisant partie du lot no sept cent soixante-dix (P.770') mesurant deux cents pieds (200') de largeur par trois cents pieds (300') de profondeur et borné comme suit: en front vers le nord-est par le boulevard Labelle, en arrière vers le sud-ouest et d'un côté vers le nord-ouest par le résidu du lot 770 appartenant à Arcade Realty Inc., de l'autre côté vers le sud-est par une partie du lot 770.La ligne nord-ouest dudit terrain étant située à 266.1' au sud-est de la ligne de division des lots 770 et 772.B) Un emplacement faisant partie du lot no sept cent soix-anvé-dix (P.770), mc3Uront trois cent vingt trois piede (323') de largeur par deux cent trente et un pieds (231') de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins et borné comme suit: en front vers le nord-ouest par une partie du lot 770, en arrière vers le sud-est et d'un côté vers le sud-ouest par une partie du lot 770 appartenant à M.Miller, de l'autre côté vers le nord-est par une partie du lot 770 appartenant à Bertrand Jutras et Miller: contenant en superficie soixante-quatorze mille six cent treize pieds carres (74,613 pi.ca.), mesure anglaise.C) Un emplacement faisant partie du lot no sept cent soixante-dix (P.770), mesurant deux cent huit pieds (208') de largeur par cent cinquante pieds (150') de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins et borné comme suit: en front vers l'est par la route no 11, en arrière vers l'ouest par une partie du lot 770 appartenant à Arthur L'Écuyer ou représentants, d'un côté vers le nord par une partie du lot 770 appartenant a Fernand Baillargeon ou représentants, de l'autre côté vers le sud par une partie du lot 770 appartenant à Arthur L'Écuyer ou représentants.$ 766.63$ 2,639.17 $3,405.80 (a) An emplacement forming part of lot number seven hundred and seventy (P.770) measuring two hundred feet (200') in width by three hundred feet (300') in depth and bounded as follows : in front on the northeast by Labelle Boulevard, in the rear on the southwest and on one side on the northwest by the remainder of lot 770 belonging to Arcade Realty Inc., on the other side on the southeast by a part of lot 770.The northwest line of the said land being situated 266.1' southeast of the division line of lots 770 and 772.(6) An emplacement forming part of lot number seven hundred and seventy (P.770) measuring three hundred and twenty-three feet (323') in width by two hundred and thirty-one feet (231') in depth, English measure, more or less and bounded as follows: in front on the northwest by a part of lot 770, in the rear on the southeast and on one Bide on the southwest by a part of lot 770 belonging to M.Miller, on the other side on the northeast by a part of lot 770 belonging to Bertrand Jutras and Miller; containing seventy-four thousand six hundred and thirteen square feet (74,613 sq.ft.) in area, English measure.(c) An emplacement forming part of lot number seven hundred and seventy (P.770), measuring two hundred and eight feet (208') in width by one hundred and fifty feet (160') in depth, English measure, more or less and bounded as follows: in front on the east by Highway No.11, in the rear on the west by a part of lot 770 belonging to Arthur L'Ecuyer or representatives, on one eide on the north by a part of lot 770 belonging to Fernand Baillargeon or representatives, on the other side on the south by a part of lot 770 belonging to Arthur L'Ecuyer or representatives.Latendresse, Mme-Mrs.Rita Simard.P.770.Un emplacement faisant partie du lot no sept cent soixante-dix (P.770), mesurant cinquante pieds (50') de largeur par quatre-vingt-dix pieds (90') de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins et borné comme suit: en front vers le sud par le chemin Notre-Dame, en arrière vers le nord par une partie du lot 770 appartenant a John Palov et al, d'un côté vers l'est par une partie du lot 770 appartenant à John Palov ou représentants, de l'autre côté vers l'ouest par une partie du lot 770 appartenant à John Palov ou représentants.Belavista Estates Inc.P.517, P.520.Des emplacements faisant partie des lots nos cinq cent dix-sept (P.517) et cinq cent vingt (P.620), mesurant mille trois cent soixante-neuf pieds (1,369') de largeur le long de la Côte St-Louis, mille cent soixante-dix pieds (1,170') de profondeur en arrière, deux mille cinquante-deux pieds et trois dixièmes de pied (2,052.3') de profondeur dans la ligne nord, cinq cent cinquante-six pieds (556') de profondeur dans la ligne sud, me sure anglaise, plus ou moins et borné comme suit: en front vers l'ouest parla Côte St-Louis et par une partie du lot 520 appartenant à Emile Taillon ou représentants, en arrière vers l'est par une partie des lots 517 et 520 appartenant a la compagnie Shawinigan Water & Power, d'un côté vers le sud par ne partie du lot 521 et par une partie du lot 520 appartenant à Emile Taillon ou représentants, de l'autre côté vers le nord par le lot 516; contenant en superficie quarante-deux arpents carrés et sept cent sept millièmes d'arpent carré (42.707 arp.ca.).Column Realty Corp.P.781.Un emplacement faisant partie du lot numéro sept cent quatre-vingt-un (P.781), mesurant un arpent de largeur approximativement, commençant avec le chemin par deux arpents de profondeur allant vers l'ouest et delà deux arpents de largeur par toute la profondeur jusqu'au chemin de fer du Pacifique Canadien; contenant en superficie vingt-huit arpents .192.32 192.32 An emplacement forming part of lot number seven hundred and seventy (P.770), measuring fifty feet (60') in width by ninety feet (90') in depth, English measure, more or less and bounded as follows: in front on the south by Notre-Dame Road, in the rear on the north hy a part of lot 770 belonging to John Palov At al, on one side on the east by a part of lot 770 belonging to John Palov or representatives, on the other side on the west by a part of lot 770 belonging to John Palov or representatives.267.02 1.276.57 1.643.69 Emplacements forming part of lots numbers five hundred and seventeen (P.617) and five hundred and twenty (P.520), measuring one thousand three hundred and sixty-nine feet (1,369') in width along Côte St-Louis, one thousand one hundred and seventy feet (1,170') in depth in the rear, two thousand fifty-two and three tenths feet (2.052.3') in depth on the north line, five hundred and fifty-six feet (666') in depth on the south line, English measure, more or less and bounded as follows: in front on the west by Côte St-Louis and by a part of lot 620 belonging to Emile Taillon or representatives, in the rear on the east by a part of lots 617 and 620 belonging to the Shawinigan Water & Power Company, on one side on the south by a part of lot 621 and by a part of lot 620 belonging to Emile Taillon or representatives, on the other side on the north by lot 516: containing forty-two and seven hundred and seven thousandths square arpents (42.707 sq.arpents) in area.1,344.69 1,245.88 $ 58.17 2,648.64 An emplacement forming part of lot number seven hundred and eighty-one (P.781) measuring about one arpent in width, starting with the road by two arpents in depth westerly and thence two arpents in width by all the depth to the Canadian Pacific railroad; containing twenty-eight square arpents (28 sq.arpents) in area, more or less and bounded as follows: on QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.I 809 carrés (28 arp.Ca.), plus ou moins et borné comme suit: vers l'ouest par la route no 11, vers l'est par le chemin de fer du Pacifique Canadien, vers le nord par une partie des lots 777 et 778 appartenant à René Papineau ou représentants, vers le sud par une partie du lot 781 appartenant à Augustin Bigras ou représentants et par une partie du lot 782 appartenant à Julien Wnelfrath ou représentants.the west by Highway No.11, on the east by the Canadian Pacific railroad, on the north by a part of lots 777 and 778 belonging to René Papineau or representatives, on the south by a part of lot 781 belonging to Augustin Bigras or representatives and by a part of lot 782 belonging to Julien Wnelfrath or representatives.Taxes Taxes Taxes scol.scol.Nome Lots et cad.munie.cath.prot.Total Names Lots and cad.Munie.Cath.Prot.taxes school school taxes taxes Baillargeon.Fernand.P.770, P.771.Un emplacement faisant partie du lot no sept cent soixante-dix (P.770), contenant en superficie soixante arpents carrés (60 arp.ca.) et borné comme suit: en front vers l'est par le chemin de la Grande Ligne en arrière vers l'ouest par les terres de la Côte Ste-Marie-Anne, d'un côté vers le nord par les lots 771 et 772 et de l'autre côté vers le sud par une partie du lot 770 appartenant à Arthur l'Écuyer ou représentants.À distraire la partie vendue a Sa Majesté le Roi aux termes d'un acte enregistré à Terrebonne sous le no 115973.Un emplacement faisant partie du lot no sept cent soixante et onze (P.771), mesurant un arpent de largeur par vingt arpents de profondeur et borné comme suit: en front par les lots 252 et 253, en arrière par le lot 770 appartenant à Joseph Vaudry, d'un côté par une partie du lot 771 appartenant à Cléophas Deguire ou représentants, de l'autre côté par une partie du lot 771 appartenant à Aldéric Ethier ou représentants.Locas, Roger.179.Locas, Roger.25.Les lots ci-dessus font partie du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Thérèse de Blainville.S 2,426.02 S 1,666.02 S 631.35 S 4,723.39 An emplacement forming part of lot number seven hundred and seventy (P.770) containing sixty square arpents (60 sq.arpents) in area, and bounded as follows: in front on the east by the Grande Ligne Road, in the rear on the west by the lands of Côte Ste-Marie-Anne.on one side on the north by lots 771 and 772 and on the other side on the south by a part of lot 770 belonging to Arthur l'Écuyer or representatives.Save and to withdraw the part sold to His Majesty the King according to the terms of a deed registered at Terrebonne under number 115973.An emplacement forming part of lot number seven hundred and seventy-one (P.771), measuring one arpent in width by twenty arpents in depth and bounded as follows: in front by lots 252 and 253, in the rear by lot 770 belonging to Joseph Vaudry, on one side by a part of lot 771 belonging to Cléophas Deguire or representatives, on the other side by a part of lot 771 belonging to Aldéric Ethier or representatives.430.94 430.94 .207.88 207.88 The abovementioned lots are part of the official cadastre of the Parish of St.Thérèse de Blainville.Commission scolaire de Sainte-Thérèse Ouest Sainte-Thérèse West School Board Capray Dev.Corp.157-110.Capray Dev.Corp.157-1II.Capray Dev.Corp.158-134 & 157-112.Capray Dev.Corp.157-113.Capray Dev.Corp.157-114.Capray Dev.Corp.157-115.Capray Dev.Corp.167-116.Capray Dev.Corp.167-138.Capray Dev.Corp.157-139.Capray Dev.Corp.157-140.Capray Dev.Corp.157-141.Capray Dev.Corp.157-291 & 158-232.Capray Dev.Corp.158-204.Entreprises Bella Inc.P.187, P.189.1) Un emplacement faisant partie du lot no cent quatre vingt-sept (P.187), mesurant sept cent dix pieds et cinquante-huit centièmes de pied (710.58') dans la ligne nord, mille huit cent quatre-vingt-quatre pieds (1,884') dans la ligne nord-est, huit cent quatre-vingt-dix-sept pieds et trente-quatre centièmes de pied (897.34') dans la ligne sud, mille six cent dix fûeds et quarante-quatre centièmes de pied (1,610.44') dans la igne sud-ouest; contenant en superficie un million quatorze mille six cent quatorze pieds carrés et soixante-douze centièmes de pied carré (1,014,614.72 pi.ca.), mesure anglaise, soit vingt-sept arpents et cinquante-sept centièmes d'arpent (27.67) et borné comme suit: vers le nord par le chemin public dit chemin de la Côte sud de Ste-Thérèse, vers le nord-est par une partie du lot 189, vers le sud par le chemin de fer du Pacifique Canadien, vers le sud-ouest par le lot 186.2) Un emplacement faisant partie du lot numéro cent quatre-vingt-neuf (P.189).mesurant huit cent quatre-vingt 23\t30\tS 31.\t26 $\t4.\t93\t8 59.\t55 21\t,77\t27.\t74\t4\t68\t54\t19 21\t93\t29.\t72\t4\t68\t50\t33 21\t.44\t27.\t19\t4.\t60\t53\t23 21\t,44\t27.\t19\t4\t60\t63\t23 21\t.44\t27\t19\t4\ton\t63.\t23 21\t44\t27\t21\t4\t.60\t53\t25 22\t23\t27.\t26\t4\t.73\t64.\t.22 22\t23\t27.\t26\t4\t.73\t64\t22 22\t23\t27\t24\t4\t73\t51\t20 22\t23\t27.\t24\t4\t.73\t51\t20 25\t42\t33.\t06\t6\t33\t63\t80 23.\t36\t30.\t63\t5\t20\t59\t18 198.\t47\t2,368.\t10\t122\t86\t3,389\t43 1) An emplacement forming part of lot number one hundred and eighty-seven (P.187) measuring seven hundred and ten and fifty-eight hundredths feet (710.58') on the north line, one thousand eight hundred and eighty-four feet (1,884') on the northeast line, eight hundred and ninety-seven and thirty-four hundredths feet (897.34') on the south line, one thousand six hundred and ten and forty-four hundredths feet (1,610.44') on the southwest line; containing one million fourteen thousand six hundred and fourteen and seventy-two hundredths square feet (1,014,614.72 sq.ft.), English measure, being twenty-seven and fifty-seven hundredths arpent (27.67) and bounded Î?.'0\"°w.s: on the north by the public road said road of the Côte Sud de Ste-Thérèse, on the northeast by a part of lot 189, on the south by the Canadian Pacific railroad, on the southwest by lot 186.2) An emplacement forming part of lot number one hundred and eighty-nine (P.189) measuring eight hundred and ninety- 810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 89 janvier 1978, 104' année, n\" 4 douze pieds et quarante-deux centièmes de pied (892.42') dans la ligne nord-est, deux cent cinquante pieds (250.0') dans la ligne sud, trois cent quatre-vingt-dix-neuf et deux dixièmes de pied (399.2') dans une ligne sud-ouest, deux cent trente-trois pieds et un dixième de pied (233.1') dans la ligne sud-est, six cent quarante-quatre pieds et soixante-dix-huit centièmes de pied (644.78') dans une autre ligne sud-ouest: contenant en superficie trois cent cinquante et un mille cent trente et un pied carré et trente-neuf centième de pied carré (351,131.39 pi.ca.), mesure anglaise et borné comme suit: dans une direction généralement nord par la rivière aux Chiens, vers le nord-est par une partie du lot 189, vers le sud par le chemin de la Côte sud de Ste-Thérèse, vers le sud-ouest par une réserve, vers le sud-est par la réserve susdite, vers ie sud-ouest par une partie du lot 187.3) Un emplacement faisant partie du lot no cent quatre-vingt-neuf (P.189), mesurant cinq cent soixante-dix-huit pieds et cinq dixièmes de pied (578.5') dans la ligne nord, quatre mille deux cent trente-trois pieds (4,233.0') et mille cent quarante-trois pieds et cinquante-quatre centièmes de pied (1,143.54') dans la ligne nord-est, cent quatre-vingt dix-neuf pieds et quarante centièmes de pied (199.40') dans la ligne sud-est, cent cinquante-huit pieds et dix centièmes de pied (158.10') dans la ligne sud-ouest, cent vingt-six pieds et quatre dixièmes de pied (126.4') dans la ligne sud-est quatre-vingt-douze pieds et cinq dixièmes de pied (92.5') dans la ligne sud-est, neuf cent quatre-vingt-six pieds et neuf centièmes de pied (986.09') et quatre mille six cent vingt-huit pieds (4,628') dans la ligne sud-ouest; contenant en superficie deux millions trois cent un mille sept cent quatre-vingt-dix-huit pieds carrés et un dixième de pied carré (2,301,798.1 pi.ca.), mesure anglaise et borné comme suit: vers le nord par le chemin de fer du Pacifique Canadien, vers le nord-est par une partie du lot 189, vers le sud-est, vers le sud-ouest et dans une deuxième ligne sud-est par le lot 98, dans une troisième ligne sud-est, par le lot 99, vers le sud-ouest par le lot 188 et par une partie du lot 187.À distraire: la partie vendue à la corporation de Ste-Thérèse Ouest aux termes d'un acte enregistré sous le No 294905: La partie vendue à General Motors aux termes d'un acte enregistré sous le No 313096: La partie vendue aux Immeubles Ste-Thérèse Ouest aux termes d'un acte enregistré sous le No 395646: Les parties subdivisées par les Entreprises Bella Inc., officiellement avant le 28 décembre 1971.two and forty-two hundredths feet (892.42') on the northeast line, two hundred and fifty feet (250.0') on the south line three hundred and ninety-nine and two tenths feet (399.2 ) on a southwest line, two hundred and thirty-three and one tenth feet (233.1') on the southeast line, six hundred forty-four and seventy-eight hundredths feet (644.78') on another southwest line; containing three hundred and fifty-one thousand one hundred and thirty-one and thirty-nine hundredths square feet (351,131.39 sq.ft.), English measure and bounded as follows: in a general northerly direction by the Rivière aux Chiens, on the northeast by a part of lot 189.on the south by the road of Côte Sud de Ste-Thérèse, on the southwest by a reserve, on the southeast by the aforesaid reserve, on the southwest by a part of lot 187.3) An emplacement forming part of lot number one hundred and eighty-nine (P.189) measuring five hundred and seventy-eight and five tenths feet (578.5') on the north line, four thousand two hundred and thirty-three feet (4.233.0') and one thousand one hundred and forty-three and fifty-four hundredths feet (1,143.54') on the northeast line, one hundred and ninety-nine and forty hundredths feet (199.40') on the southeast line, one hundred and fifty-eight and ten hundredths feet (158.10') on the southwest line, one hundred and twenty-six and four tenths feet (126.4').on the southeast line, ninety-two and five-tenths feet (92.5'), on the southeast line, nine hundred and eighty-six and nine hundredths feet (986.09') and four thousand six hundred and twenty-eight feet (4,628') on the southwest line; containing two million three hundred and one thousand seven hundred and ninety-eight and one tenth square feet (2,301,798.1 sq.ft.), English measure and bounded as follows: on the north by the Canadian Pacific railroad, on the northeast by a part of lot 189, on the southeast, southwest and in a second southeast line by lot 98, in a third southeast line hy lot 99, on the southwest by lot 188 and by a part of lot 187.Save and to withdraw the part sold to the Corporation of St.Thérèse West according to the terms of a deed registered under number 294905: The part sold to General Motors according to the terms of a dee*d registered under number 313096: The part sold to Immeubles Ste-Thérèse Ouest according to the terms of a deed registered under number 395646: The parts officially subdivided by Entreprises Bella Inc.before December 28, 1971.Taxea Taxes Taxes scol.scol.Noms Lots et cad.munie.cath.prot.Total Names Lots and cad.Munie.Cath.Prot.taxes school school taxes taxes Graft Billo Associates Inc.158-88.Graft Billo Associates Inc.168-89.Graft Billo Associates Inc.168-90.Graft Billo Associates Inc.168-91.Graft Billo Associates Inc.158-92.Graft Billo Associates Inc.168-93.Graft Billo Associates Inc.158-94.Graft Billo Associates Inc.158-95.Graft Billo Associates Inc.168-96.Robert, A.Guay Const.187-10.Robert, A.Guay Const.187-23.Ste-Thérèse West Land Corp.157-245.Ste-Thérèse West Land Corp.158-239.Saguenay Holding Inc.169-3.Saguenay Holding Inc.159-4.Saguenay Holding Inc.159-5.Saguenay Holding Inc.169-6.Saguenay Holding Inc.169-7.Saguenay Holding Inc.169-8.Saguenay Holding Inc.159-9.Saguenay Holding Inc.159-10.Saguenay Holding Inc.169-11.Saguenay Holding Inc.169-12.Saguenay Holding Inc.169-23.$ 21.44\t$ 29.65\t8 5.72\tS 56.81 21.44\t27.21\t5.72\t54.37 21.44\t27.21\t6.72\t54.37 21.44\t27.21\t5.72\t54.37 21.44\t27.21\t5.72\t54.37 21.44\t27.21\t4.58\t53.23 21.44\t27.21\t4.58\t53.23 21.44\t27.21\t4.58\t53.23 21.44\t27.21\t4.58\t53.23 \t904.69\t\t904.59 \t903.26\t\t903.26 3.95\t18.09\t\t22.04 13.74\t33.62\t\t47.36 43.86\t62.30\t4.83\t110.99 43.22\t57.93\t4.83\t105.98 44.18\t69.93\t4.83\t108.94 45.13\t60.86\t4.85\t110.84 47.04\t63.43\t4.88\t115.35 19.70\t24.48\t4.36\t48.53 19.70\t24.48\t1.80\t45.98 19.70\t24.49\t1.80\t45.99 19.70\t24.49\t1.80\t45.99 19.70\t24.49\t1.80\t45.99 62.20\t75.47\t6.32\t133.99 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.I 811 Taxes Taxes Taxes scol.scol.Noms Lots et cad.munie.cath.prot.Total Names Lots and cad.Munie.Cath.Prot.taxes school school taxes taxes Saguenay Holding Inc.159-24.Saguenay Holding Inc.¦.159-26.Saguenay Holding Inc.159-27.Saguenay Holding Inc.159-28.Saguenay Holding Inc.159-35.Saguenay Holding Inc.159-36.Saguenay Holding Inc.169-37.Saguenay Holding Inc.159-38.Saguenay Holding Inc.159-39.Saguenay Holding Inc.159-40.Saguenay Holding Inc.159-41.Saguenay Holding Inc.159-43.Saguenay Holding Inc.159-44.Saguenay Holding Inc.159-45.Saguenay Holding Inc.159-46.Saguenay Holding Inc.- 159-47.Saguenay Holding Inc.- 159-48.Saguenay Holding Inc.159-49.Saguenay Holding Inc.159-50.Saguenay Holding Inc.159-51.Saguenay Holding Inc.159-52.Saguenay Holding Inc.159-53.Saguenay Holding Inc.159-54.Saguenay Holding Ine.¦.159-63.Saguenay Holding Inc.159-64.Saguenay Holding Inc.159-65 .Saguenay Holding Inc.159-66.Saguenay Holding Inc.159-67.Saguenay Holding Inc.159-68.Saguenay Holding Inc.159-69.Saguenay Holding Inc.159-70.Saguenay Holding Inc.159-71.Saguenay Holding Inc.159-72.Saguenay Holding Inc.159-73.Saguenay Holding Inc.159-74 .Saguenay Holding Inc.159-75.Saguenay Holding Inc.159-76.Saguenay Holding Inc.159-77.Saguenay Holding Inc.159-78.Saguenay Holding Inc.159-79.Saguenay Holding Inc.159-S0.Saguenay Holding Inc.159-S1.Saguenay Holding Inc.159-82 Saguenay Holding Inc.159-83.Saguenay Holding Inc.159-84 Saguenay Holding Inc.159-85.Saguenay Holding Inc.159-86.Saguenay Holding Inc.159-87.Saguenay Holding Inc.159-88.Saguenay Holding Inc.159-89 .Saguenay Holding Inc.159-90.Saguenay Holding Inc.159-91.Saguenay Holding Inc.159-92.Saguenay Holding Inc.159-93 .Saguenay'Holding Inc.159-94 .Saguenay Holding Inc.159-95.Saguenay Holding Inc.159-96.Saguenay Holding Inc.159-97.Saguenay Holding Inc.159-9S.Saguenay Holding Inc.159-99 .Saguenay Holding Inc.\u2022> .\u2022 \u2022 159-100 Saguenay Holding Inc.159-101.Saguenay Holding Ine,.159-102.Saguenay Holding Inc.159-103.Saguenay Holding Inc.159-104.Saguenay Holding Inc.159-105.Saguenay Holding Inc.159-106.Saguenay Holding Inc.159-114.Saguenay Holding Inc.159-115.Saguenay Holding Inc.159-116.8 32.11\t8 31.58\tS 2.45\tS 66.14 66.74\t86.80\t7.30\t160.84 18.91\t24.42\t1.75\t45.08 18.91\t24.42\t1.75\t45.08 27.89\t33.83\t2.65\t64.37 26.06\t32.13\t2.49\t60.68 20.34\t26.52\t1.89\t47.76 21.13\t26.67\t2.00\t49.80 22.72\t27.76\t2.16\t52.62 20.17\t25.00\t1.90\t47.07 18.58\t23.92\t1.72\t44.22 1.9.70\t24.45\t1.80\t45.95 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.68\t23.92\t1.75\t44.25 17.18\t23.92\t1.75\t42.85 23.03\t28.26\t1.25\t52.54 21.60\t27.13\t2.18\t50.91 20.01\t25.00\t1.95\t46.96 18.58\t23.92\t1.75\t44,25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 22.87\t28.29\t2.13\t53.29 23.20\t28.76\t2.18\t64.14 18.91\t24.42\t1.84\t45.17 18.91\t24.42\t1.84\t45.17 18.91\t24.42\t1.84\t45.17 18.91\t24.42\t1.84\t45.17 23.51\t29.31\t2.24\t55.06 22.87\t28.23\t2.18\t53.28 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 22.87\t28.30\t2.15\t53.32 17.95\t23.20\t1.73\t42.88 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.68\t23.92\t1.75\t44.25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 21.29\t26.67 '\t2.02\t49.98 21.60\t27.19\t2.07\t50.86 19.38\t23.92\t1.91\t45.21 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.68\t23.92\t1.75\t44.25 20.34\t25.49\t1.96\t47.79 27.32\t33.70\t2.68\t63.70 21.60\t27.20\t2.15\t50.95 18.68\t24.43\t1.85\t44.96 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 22.56\t27.75\t2.18\t52.49 1.76\t4.02\t\t5.78 3.02\t4.86\t\t7.88 18.27\t23.39\t1.75\t43.41 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.58\t.23.92\t1.75\t44.25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 22.87\t28.30\t2.18\t53.35 22.87\t28.30\t2.18\t53.35 18.68\t23.92\t1.76\t44.25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.58\t23.92\t1.75\t44.25 18.68\t23.92\t1.76\t44.25 2.55\t4.86\t0.28\t7.69 19.70\t24.44\t2.01\t46.15 16.05\t21.15\t1.61\t38.81 16.06\t21.16\t1.61\t38.81 812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, IQk* année, n° 1 \t\t\tTaxes\tTaxes \t\tTaxes\tscol.\tscol.Noms\tLots et cad.\tmunie,\tcath.\tprot.Names\tLots and cad.\tMunie.\tCath.\tProt.\t\ttaxea\tschool\tschool \t\t\ttaxes\ttaxes Total Saguenay Holding Inc.169-117.Saguenay Holding Inc.159-118.Saguenay Holding Inc.159-119.Saguenay Holding Inc.159-120.Saguenay Holding Inc.159-121.Saguenay Holding Inc.159-122, P.159- Saguenay Holding Inc.159-123, P.159.Un emplacement faisant partie du lot No cent cinquante-neuf (P.159) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Thérèse-de-Blainville, étant bomé comme suit: vers le nord-est par les lots 160 et 161 et par une partie du lot 159 réservé par Phillipe Dion, vers le sud-est par le lot 160 et par une partie des lots 109 et 159, vers le sud-ouest par les subdivisions du lot originaire 158 et par une partie du lot 159 réservé par Phillipe Dion, vers le nord-ouest par le chemin de la Rivière Cachée et par une partie du lot 159 réservé par Phillipe Dion.Tel que plus amplement décrit sur un plan préparé par Fernand Lemay et portant le No 6633A.A distraire: La partie expropriée par la Voirie aux termes d'un acte enregistré sous le No 358275.Les parties subdivisées par Saguenay Holdings Inc., officiellement avant le 28 décembre 1971.16.05 16.05 16.05 17.35 21.60 37.33 31.76 21.15 21.15 21.15 21.71 27.20 54.18 48.18 1.61 1.61 1.61 1.65 2.18 3.58 2.98 S 38.81 38.81 38.81 40.71 60.98 95.09 82.92 An emplacement forming part of lot number one hundred and fifty-nine (P.159) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Thérèse-de-Blainville bounded as follows: on the northeast by lots 160 and 161 and by a part of lot 159 reserved by Phillipe Dion, on the southeast by lot 160 and by a part of lots 109 and 159, on the southwest by the subdivisions of original lot 158 and by a part of lot 159 reserved by Phillipe Dion, on the northwest by Chemin de la Rivière Cachée and by a part of lot 159 reserved by Philippe Dion.As more fully described in a plan executed by Fernand Lemay numbered 6633A.Save and to withdraw : The part expropriated by the Department of Roads according to the terms of a deed registered under number 358275: The parts officially subdivided by Saguenay Holdings Inc.before December 28, 1971.Saguenay Holding Inc.159-124.Saguenay Holding Inc.159-125.Saguenay Holding Inc.169-126.Saguenay Holding Inc.159-127.Terrebonne Gen.Dev.187-17.Terrebonne Gen.Dev.187-75.Terrebonne Gen.Dev.187-76, 189-56.Terrebonne Gen.Dev.187-77, 189-55.Terrebonne Gen.Dev.187-78,189-54.Terrebonne Gen.Dev.187-79, 189-53.Terrebonne Gen.Dev.187-80, 189-52.Terrebonne Gen.Dev.187-81, 189-51.Terrebonne Gen.Dev.187-82, 189-60.Terrebonne Gen.Dev.187-83.189-49.Terrebonne Gen.Dev.187-84, 189-48.Terrebonne Gen.Dev.187-85, 189-47.Terrebonne Gen.Dev.187-86.Terrebonne Gen.Dev.187-87.Terrebonne Gen.Dev.187-88.\u2022.Terrebonne Gen.Dev.187-89.Terrebonne Gen.Dev.187-90.Terrebonne Gen.Dev.187-91.Terrebonne Gen.Dev.187-92.Terrebonne Gen.Dev.187-93.Terrebonne Gen.Dev.187-94.Terrebonne Gen.Dev.187-95.Terrebonne Gen.Dev.187-96.Terrebonne Gen.Dev.187-97.Terrebonne Gen.Dev.'.187-98.Terrebonne Gen.Dev.187-99.Terrebonne Gen.Dev.187-100.Terrebonne Gen.Dev.189-41.Terrebonne Gen.Dev.189-42.Terrebonne Gen.Dev.189-43.Terrebonne Gen.Dev.189-44.Terrebonne Gen.Dev.189-45.Terrebonne Gen.Dev.189-46.Terrebonne Gen.Dev.189-67, 189-58, 189-59, 189-60, 189-61.189-62.Terrebonne Gen.Dev.187-113, 187-114, 187-115.187-116, 187-117, 187-118, 187-119, 187-120, 187-121, 187-122.Terrebonne Gen.Dev.P.187.P.189._ 1) Un emplacement faisant partie du lot no cent quatre-vingt-sept (P.187), mesurant huit cent quatre-vingt-huit pieds 31.76\t38.18\t2.98\t72.92 31.76\t38.18\t2.98\t72.9?31.76\t38.18\t2.98\t72.92 38.44\t46.39\t3.58\t88.4} 912.19\t71.64\t6.01\t989.84 27.03\t32.81\t3.01\t62.85 88.69\t105.17\t9.83\t203.69 88.69\t105.17\t9.83\t203.69 81.20\t202.81\t9.83\t293.84 81.20\t202.81\t9.83\t293.84 89.32\t105.85\t9.85\t205.02 517.37\t105.85\t9.85\t633.07 515.68\t106.06\t9.85\t631.69 615.68\t106.04\t9.85\t631.67 315.70\t121.14\t11.34\t448.18 13.99\t19.98\t1.45\t35.42 13.99\t17.98\t1.45\t33.42 13.99\t17.98\t1.46\t33.42 23.85\t29.18\t2.60\t55.63 23.85\t29.18\t2.60\t55.63 13.99\t17.98\t1.45\t33.42 13.99\t17.98\t1.45\t33.42 23.85\t29.18\t2.60\t55.63 23.85\t29.18\t2.60\t65.63 13.99\t17.98\t1.45\t33.42 13.99\t17.98\t1.45\t33.42 13.99\t17.98\t1.45\t33.42 13.99\t17.98\t1.45\t33.42 13.99\t17.98\t1.45\t33.42 13.99\t17.98\t1.45\t33.42 605.19\t221.00\t21,24\t747.43 1.990.07\t416.82\t39.53\t2,446.42 1,358.54\t917.98\t88.84\t2,365.36 24.49\t29.97\t2.65\t57.11 13.99\t17.98\t1.45\t33.42 13.99\t17.98\t1.45\t33.42 13.99\t.17.98\t1.45\t33.42 2,741.84\t333.99\t24.33\t3,100.16 7,224.25\t573.05\t41.70\t7,839.00 13,920.21\t6,402.55\t607.02\t20,829.78 1) An emplacement forming part of lot number one hundred and eighty-seven (P.187) measuring eight hundred and eighty- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 89, 1978, Vol.104, No.4 813 (888.0') dans la ligne nord, quatre mille six cent vingt-huit pieds (4,628') dans la ligne nord-est, cinq cent quatre-vingt-trois pieds et un dixième de pied (583.1') dans la ligne sud-est, cinq mille deux cent soixante-treize pieds et deux dixièmes de pied (5,273.2,) dans la ligne sud-ouest; contenant en superficie deux millions huit cent soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-seize pieds carrés et quatre dixièmes de pied carré (2,878,996.4 pi.ca.) mesure anglaise et borné comme suit: vers le nord par le chemin de fer Canadien Pacifique, vers le nord-est par une partie du lot 189, vers le sud-est par le lot 188, vers le sud-ouest par le lot 186.A distraire: Toutes les parties subdivisées dudit lot, officiellement avant le 28 décembre 1971, 2) Un emplacement faisant partie du lot No cent quatre-vingt-neuf (P.189) mesurant cinq cent sept pieds et quarante-six centièmes de pied (507.46') dans la ligne nord, deux mille deux pieds et six dixièmes de pied (2,002.6') dans la ligne nord-est, cinq cent quatre-vingt-un pieds et soixante-neuf centièmes de pied (581.69') dans la ligne sud, mille huit cent quatre-vingt-quatre pieds (1,884.0') dans la ligne sud-ouest; contenant en superficie huit cent treize mille vingt-trois pieds carrés et cinq dixièmes de pied carré (813,023.5 pi.ca.), mesure anglaise et borné comme suit: au nord par le chemin de la Côte sud de Ste-Thérèse, au nord-est par une partie du lot 189, au sud par le chemin de fer du Pacifique Canadien, vers le sud-ouest par une partie du lot 187.A distraire: La partie vendue à la paroisse de Ste-Thérèse Ouest aux termes d'un acte enregistré sous le No 294420: Toutes les parties subdivisées dudit lot, officiellement avant le 28 décembre 1971.eight feet (888.0') on its north line, four thousand six hundred and twenty-eight feet (4,628') on the northeast line, five hundred and eighty-three and one tenth feet (683.1') on the southeast line, five thousand two hundred and seventy-three and two tenths feet (5,273.2') on the southwest line; containing two million eight hundred and seventy-eight thousand nine hundred and ninety-six and four tenths square feet (2,878,996.4 sq.ft.) English measure and bounded as follows: on the north by the Canadian Pacific railroad, on the northeast by a part of lot 189, on the southeast by lot 188, on the southwest by lot 186: Save and to withdraw: All parts of the said lot officially subdivided before December 28, 1971.2) An emplacement forming part of lot number one hundred and eighty-nine (P.189) measuring five hundred and seven and forty-six hundredths feet (507.46') on the north line, two thousand and two and six tenths feet (2,002.6') on the northeast line, five hundred and eighty-one and sixty-nine hundredths feet (581.69') on the south line, one thousand eight hundred and eighty-four feet (1,884.0') on the southwest line; containing eight hundred and thirteen twenty-three and five tenths square feet (813,023.5 sq.ft.) in area, English measure and bounded as follows: on the north by Chemin de la Côte Sud de Ste-Thérèse, on the northeast by a part of lot 189, on the south by the Canadian Pacific railroad, on the southwest by a part of lot 187.Save and to withdraw: The part sold to the Parish of Ste-Thérèse Ouest according to the terms of a deed registered under number 294420: All parts of the said lot officially subdivided before December 28, 1971.Taxes Taxes Taxes scol.scol.Noms Lots et cad.munie.cath.prot.Total Names Lots and cad.Munie.Cath.Prot.taxes school school taxes taxes V.V.D'Astour Const.Ltée.101-140,.V.V.D'Astour Const.Ltée.101-141.Domaine Blainville Inc.P.84.Un emplacement faisant partie du lot numéro quatre-vingt-quatre (P.84), mesurant cent vingt-neuf pieds (129') dans la ligne nord-est, cinq cent dix-huit pieds et cinquante-deux centièmes de pied (518.52') dans une autre ligne nord-est, trois cent soixante-dix pieds et cinq dixièmes de pied (370.5') dans la ligne sud, quatre cent quatre-vingt-douze pieds et quatre-vingt-huit centièmes de pied (492.88') dans la ligne sud-ouest, deux cent trente et un pieds et soixante-neuf centièmes de pied (231.69') dans une ligne nord-ouest, cent vingt-six pieds et soixante-quatorze centièmes de pied (126.74') dans une autre ligne nord-ouest; contenant en superficie deux cent deux mille trois cent trente-quatre pieds carrés (202.334 pi.ca.), mesure anglaise, plus ou moins et borné comme suit: vers le nord-ouest par la Route No 29, vers le nord-est par une partie du lot 82 et par les lots 82-27, 28 et 29, vers le sud par le lot 84-146.vers le sud-ouest par le lot 84-145.A distraire: Les parties subdivisées par le Domaine Blainville Inc.officiellement avant le 28 décembre 1971.$ 502.41 $ 73.67 S 576.08 .604.04 73.67 577.71 \u201e.$6.609.82 280.72 23.50 6.914.04 An emplacement forming part of lot number eighty-four (P.84) measuring one hundred and twenty-nine feet (129') on the northeast line, five hundred and eighteen and fifty-two hundredths feet (518.62') on another northeast line, three hundred and seventy and five tenths feet (370.5') on the south line, four hundred and ninety-two and eighty-eight hundredths feet (492.88') on the southwest line, two hundred and thirty-one and sixty-nine hundredths feet (231.69') on a northwest Une, one hundred and twenty-six and seventy-four hundredths feet (126.74') on another northwest line; containing two hundred and two thousand three hundred and thirty-four square feet (202,334 sq.ft.) in area, English measure, more or less and bounded as follows: on the northwest by Highway No.29, on the northeast by a part lot 82 and by lots 82-27, 28 and 29, on the south by lot 84-146, on the southwest by lot 84-145.Save and to withdraw: The parts officiary subdivided by Domaine BlainviUe Inc.before December 28, 1971.Domaine Blainville Inc.84-320.Domaine Blainville Inc.84-322.Domaine Blainville Inc.84-323.Boutin, Urbain.187-12.Boutin, Urbain.187-8.Carrière, Jacques.P.117 (devenu-now) 117-79, 117-80.Un emplacement faisant partie du lot numéro cent dix-sept (P.117), mesurant quatre-vingt-cinq pieds et deux dixièmes de pied (85.2') dans la ligne nord-ouest, soixante-treize pieds (73') dans la ligne sud-est par une profondeur de cent cinquante-cinq pieds (165') dans la Ugne nord-est et cent vingt-six pieds et deux dixièmes de pied (126.2') dans la ligne sud-est; contenant en superficie dix mille six cent quatre-vingt-dix pieds carrés (10,690 pi ca.), mesure anglaise, plus ou 1,470.01 1,726.39 628.97 630.69 1,267.19 1,170.34 43.72 924.24 923.69 414.92 122.67 113.28 4.21 2,859.87 3,010.01 676.90 924.24 923.69 1,045.61 An emplacement forming part of lot number one hundred and seventeen (P.117) measuring eighty-five and two tenths feet (85.2') on the northwest line, seventy-three feet (73') on the southeast line by a depth of one hundred and fifty-five feet (155') on the northeaBt line and one hundred and twenty-six and two tenths feet (126.2') on the southeast line; containing ten thousand six hundred and ninety square feet (10,690 sq.ft.), English measure, more or less and bounded as fullowB: 814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 moins et borné come suit: en front vers le nord-ouest par le chemin public de la Grande Côte, d'un côté vers le nord-est par une partie du lot 117, en arrière vers le sud-est par le lot 117-74, de l'autre côté vers le 6ud-ouest par le lot 117-71.in front on the northwest by the Chemin Public de la Grande Côte, on one side on the northeast by a part of lot 117, in the rear on the southeast by lot 117-74, on the other side on the southwest by lot 117-71.Taxes Taxes Taxes scol.scol.Noms Lots et cad.munie.cath.prot.Total Names Lots and cad.Munie.Cath.Prot.taxes school school taxes taxes Carrière, Jacques.117-74.Carrière.Jacques.117-75.Carrière, Jacques.117-76.Comtois, Roland.117-10.Daneau, Gilles.189-21.Deslauriers & Auger.P.122.Un emplacement connu et désigné comme étant une partie du lot numéro cent vingt-deux (P.122), mesurant deux cent quatre-vingt-quatorze pieds (294') dans la ligne sud-est, en front cinq mille cent huit pieds et cinq dixièmes de pied (5,108.5') dans la ligne nord-est, deux cent quatre-vingt-six pieds et cinq dixièmes de pied (286.5') dans la ligne nord-ouest, cinq mille cent soixante-dix pieds (5,170') dans la ligne sud-ouest; contenant en superficie quarante arpents et trente-quatre centièmes d'arpents (40.34 arp.) équivalent à un million quatre cent quatre-vingt-quatre mille six cent trois pieds carrés (1,484,603 pi.ca.) mesure anglaise, plus ou moins et borné comme suit: en front vers le sud par la Grande Côte, en arrière vers le nord par la concession de la Rivière Cachée et par le lot 145, d'un côté vers l'est par le lot 121, de l'autre côté vers l'ouest par le lot 123.Désormeaux, Bernard.162-32.Gilbert, Emile.108-122.Labonté.Maurice.101-47.Lamarche, Yvan.103-89____.Luciano, Riolando.129-27, 129-P.28.Un emplacement connu et désigné comme étant une partie du lot vingt-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent vingt-neuf (129-P.28), mesurant en suivant la ligne de la rue étant le lot 129-61, quatre-vingt-douze pieds et quatre-vingt-trois centièmes de pied (92.83') et mesurant quarante pieds (40') de profondeur dans la ligne sud-ouest et soixante-dix pieds (70') de profondeur dans Ta ligne sud-est; contenant en superficie deux mille quatre cent cinquante-sept pieds carrés (2,457 pi.ca.), mesure anglaise, plus ou moins.Massy, André.79-30-20.Michaud.Arthur.117-58.Michaud, Arthur.117-69.Moisan, Lionel.123-21.Ouimet, Jean-Guy.P.179.Tout le lot cent soixante-dix-neuf (179) des plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Ste-Thérèse-de-Blainville, sauf et excepté: a) la partie vendue à René Caron aux termes d'un acte enregistré a Terrebonne sous le numéro 195131.b) la partie vendue à Joseph Hamelin aux termes d'un acte enregistré à Terrebonne sous le numéro 220769.c) la partie vendue à Odina Croteau ou représentants aux termes d'un acte enregistré à Terrebonne sous le numéro 233215.Paquette, René.108-61.Paquette.René.108-51.Pilon, Denis.103-28.Quesnel Oscar et al.108-P.126.Un emplacement connu et désigné comme étant une partie du lot cent vingt-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent huit (108-P.126), mesurant cinquante pieds (50') de largeur en avant et cent dix-huit pieds (118') de largeur en arrière par cent cinquante et un pieds (161') de profondeur dans la ligne sud-ouost et oont trcntc-oix pieds et six dixièmes $ 35.76 434.37 418.97 328.08 1,791.89 ( 51.71 800.67 671.60 462.42 1,306.13 2,304.18 $ 87.47 1,234.94 990.57 780.50 1,306.13 4,096.07 An emplacement known and designated as being a part of lot number one hundred and twenty-two (P.122) measuring two hundred and ninety-four feet (294') on the southeast line, in front five thousand one hundred and eight and five tenths feet (5,108.5') on the northeast line, two hundred and eighty-six and five tenths feet (286.5') on the northwest line, five thousand one hundred and seventy feet (5.170') on the southwest line; containing forty and thirty-four hundredths arpents (40.34 arpents) equivalent to one million four hundred and eighty-four thousand six hundred and three square feet (1,484,603 sq.ft.) English measure, more or less and bounded as follows: in front on the south by Grande Côte, in the rear on the north by the Concession de la Rivière Cachée and by lot 145, on one side on the east by lot 121, on the other side on the west by lot 123.4,839.70 121.31 348.32 7,997.70 167.86 376.05 268.23 687.36 12,837.40 289.17 724.37 268.23 687.36 An emplacement known and designated as being a part of lot twenty-eight of the official subdivision of original lot number one hundred and twenty-nine (129 P.28) measuring along the line of the street, namely lot 129-61, ninety-two and eighty-three hundredths feet (92.83') and forty feet (40') in depth on the southwest line and seventy feet (70') in depth on the southeast line; containing two thousand four hundred and fifty-seven square feet (2,457 sq.ft.) in area, English measure, more or less.717.81 26.63 262.68 188.97 632.46 38.36 483.68 109.65 900.16 1,350.27 64.89 746.36 109.65 1,089.13 All of lot one hundred and seventy-nine (179) in the officia' plan and book of reference of the Parish of St.Thérèse-de-Blainville.save and to withdraw: (a) the part sold to René Caron according to the terms of a deed registered at Terrebonne under number 195131.(6) the part sold to Joseph Hamelin according to the terms of a deed registered at Terrebonne under number 220769.(c) the part sold to Odiana Croteau or representatives according to the terms of a deed registered at Terrebonne under number 233215.969.40 187.21 80.90 187.16 412.07 116.60 80.90 187.16 1,371.47 303.81 An emplacement known and designated as being a part of lot one hundred and twenty-six of the official subdivision of original lot number one hundred and eight (108 P.126) measuring fifty feet (50') in width in front and one hundred and eighteen feet (118') in width in the rear by one hundred and fifty-one foot (151') in depth on the southwest line and one QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 815 de pied (136.6') de profondeur dans la ligne sud-est, mesure anglaise.A distraire: La partie vendue à la Ville de Ste-Thérèse Ouest aux termes d'un acte de vente enregistré sous le No 291902.Robert, Yvon.123-122, 124-17____ Robert, Yvon.124-81.St-Georges, René.108-77.Tremblay, Régimbald.187-14.Les lots ci-dessus font partie du cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Thérèse de Blainville.hundred and thirty-six and six tenths feet (136.6') in depth on the southeast line, English measure.Save and to withdraw: The part sold to the Town of St.Thérèse West according to the terms of a deed of sale registered under number 291992.Taxes Taxes scol.scol.cath.prot.Total Cath.Prot.school school taxes raxes .$ S 171.31 8 171.31 .41.60 13.91 55.51 .144.35 199.63 343.98 .923.76 923.75 The lots abovementioned are part of the official cadastre of the Parish of St.Thérèse de Blainville.Taxes Noms Lots et cad.munie.Names Lots and cad.Munie.taxes Municipalité de Sainte-Sophie \u2014 Municipality of Sainte-Sophie Taxes Taxes Noms Lots et cad.Rang munie.scol.Total Names Lots and cad.Range Munie.School taxes taxes Bruyère.Maurice.67-5.$ 63.38 S 63.38 Tel qu'acquis par acte No 360765, avec bâtisses.As purchased by deed No.360765, with buildings.Potrasal, Steve.P.89.316.30 316.30 Superficie 31,800, acquis par acte No 233391, avec bâtisses.Area 31,800, purchased by deed No.233391, with buildings.Perreault, Gilbert.P.277 .243.20 S 142.73 385.93 Superficie 20,000 pi.ca.tel qu'acquis par acte No 261477, Area 20,000 sq.ft.as purchased by.deed No.261477, with avec bâtisses buildings.Tessier, Jean-Marie;:________P.284.373.59 373.59 Superficie 20,000 pi.ca.tel qu'acquis par acte No 372627, Area 20,000 sq.ft.as purchased by deed No.372627, with avec bâtisses.buildings.Boisvert, Mildred.P.317.76.53 135.06 211.59 Superficie 9,000 pi.ca.tel qu'acquis par acte No 255476, Area 9,000 sq.ft.as purchased by deed No.255476, with avec bâtisses.buildings.Ethier, Marcel.P.341.102.70 102.70 Superficie 10,000 pi.ca., tel qu'acquis par acte No 336259, Area 10,000 sq.ft., as purchased by deed No.336259, with avec bâtisses.buildings.Les Valeurs Concorce Ltée.P.352.106.29 106.29 Superficie 73.93 a.c.tel qu'acquis par acte No 372336 et Area 73.93 sq.a., as purchased by deed No.372335& 373161.373161.Thibodeau, Real.367-16.18.31 18.31 Tel qu'acquis par acte No 363108.As purchased by deed No.363108.Goyette, Michel.P.367.15.11 16.11 Superficie 5,000 pi.ca., tel qu'acquis par acte No 357069.Area 5,000 sq.ft., as purchased by deed No.357069.Tessier.Roger.P.368-P.369.84.39 84.39 Superficie 10,000 pi.ca\u201e acquis par acte No 315422.Area 10,000 sq.ft., purchased by deed No.315422.Aubert & Girard.P.368.30.37 30.37 Superficie 6,000 pi.ca., acquis par acte No 331760.Area 6,000 sq.ft., purchased by deed No.331760.Séguin, Jacques.P.368 .98.87 98.87 Superficie 6,000 pi.ca., acquis par acte No 332672, avec Area 6,000 sq.ft., purchased by deed No.332572.with bâtisses.buildings. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° j Taxea Taxes Noms Lots et cad.Rang munie.scol._ _ Names Lots and cad.Range Munie.School taxes taxes Gagnon, Leopold.P.369.$ 28.58 » 28.68 Superficie 5.000 pi.ca.acquis par acte No 32S688.Area 6,000 sq.ft., purchased by deed No.328688.Bourassa, Henri.P.369-P.368.115.26 115.26 Superficie 5,000 pi.ca., acquis par acte No 330658, avec Area 5.000 sq.ft., purchased by deed No.330658, with bâtisses, buildings.Paradis.Raymond.P.369 .70.96 70.96 Superficie 5.000 pi.ca., acquis par acte No 353855, avec bâtis- Area 6,000 sq.ft., purchased by deed No.353855, with ses.buildings.Whitney, Lyman.P.383.13.61 13.51 Superficie 36,800 pi.ca., acquis par acte No 288162.Area 36,800 sq.ft., purchased by deed No.288162.Tissenbaum.Seymour.P.387.169.67 128.88 298.65 Superficie 77.8 a.c, acquis par actes 234865 et 324852.Area 77.8 sq.a., purchased by deed Nos 234865 4 324852.Tissenbaum, Seymour.P.388.134.82 110.80 245.62 Superficie 55 a.c, acquis par actes Nos 234866 & 324862.Area 55 sq.a., purchased by deed Nos 234866 & 324852.Morin.Mme-Mrs.Gertrude.P.389.15.11 16.11 Superficie 6.045 pi.ca., acquis par acte No.365679.Area 6,045 sq.ft., purchased by deed No.365679.Gray, Floyd.P.418.69.86 69.86 Superficie 8,250 pi.ca., acquis par acte No 290055, avec Area 8,250 sq.ft., purchased by deed No.290065, with bâtisses.buildings.Ott, George.P.434.20.61 20.61 Superficie 7,500 pi.ca., acquis par acte No 243710.Area 7,600 sq.ft., purchased by deed No.243710.Lebrun, Gabriel.438-6.93.07 93.07 Acquis par acte No 298648, avec bâtisse.Purchased by deed No.298648, with buildings.Roch, Claude.439-172-176.142.22 142.22 Acquis par acte No 364192, avec bâtisse.Purchased by deed No.364192, with buildings.Brissette, Léo.458-3-4-P.6 .209.26 209.26 Superficie 1,350 pi.ca., acquis par acte No.232747 avec Area 1,350 sq.ft., purchased by deed No.232747, with bâtisses.buildings.Page, Marcel.P.459.20.44 20.44 Superficie 10,000 pi.ca., acquis par acte No 327674.Area 10,000 sq.ft., purchased by deed No.327674.Municipalité scolaire protestante de Laurentia Protestant school municipality of Laurentia Lechter.M.-Mr.Benjamin.224-269.Klug.Mile-Miss Freda.P.164.Partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro cent soixante-quatre (P.164), mesurant cent quinze pieds (116') de largeur sur cent pieds (l00') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins; borné comme suit; en front vers le sud-est par le chemin public ou route 41 ; en arrière, vers le nord-ouest, par autre partie du lot numéro 164 demeurant la propriété de la venderesse (St-Jérôme Properties Inc.); d'un côté vers le sud-ouest par l'emplacement appartenant à M.Moe Greenstone et de l'autre côté vers le nord-est par l'emplacement appartenant à Dame Ida Weinstein-Yaphe.Pilot.M.-Mr.Wakeham.P.163.Partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro cent soixante trois (P.163), mesurant cent vingt-deux pieds et trente-trois centièmes de pied (122.33') de largeur; sur cent pieds (100') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins; .S 659.18 8 669.18 .8 26.24 38.73 64.97 Part of the lot of land known and designated under number one hundred and sixty-four (164) measuring one hundred and fifteen feet (115') in width by one hundred feet (100') in depth, English measure and more or less, bounded as follows: in front on the southeast by the public road or Highway 41; in the rear on the northwest by another part of lot number 164 remaining the property of the vendor (St-Jérôme Properties Inc.); on one side on the southwest by the emplacement belonging to Mr.Moe Greenstone and on the other side on the northeast by the emplacement belonging to Mrs.Ida Weinstein-Yaphe.37.98 37.98 Part of the lot of land known and designated under number one hundred and sixty-three (P.163) measuring one hundred and twenty-two and thirty-three hundredths feet (122.33') in width by ona hundred feet (100') in depth, English measure QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10i, No.4 817 Taxes Taxes Noms Lots et cad.Rang munie.scol.Total Names Lots and cad.Range Munie.Sobool taxes taxes borné comme suit: en front vers le sud-est par le chemin public ou route 41, en arrière vers le nord-ouest par autre partie du lot numéro 163 demeurant la propriété de la venderesse (St.Jérôme Properties Inc.); d'un côté vers le nord-est par la rue No 163-1 et de l'autre côté vers le sud-ouest par l'emplacement appartenant à M.Harry H.Elliott.and more or less; bounded as follows: in front on the southeast by the public road or Highway 41, in the rear on the northwest by another part of lot number 163 remaining the property of the vendor (St-Jérôme Properties Inc.); on one side on the north-east by street No.163-1 and on the other side on the southwest by the emplacement belonging to Mr.Harry H.Elliott.Richman, Mme-Mrs.Herman.P.164.Partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro cent soixante-quatre (P.164), mesurant cent quinze pieds (115') de largeur sur cent pieds (100') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins: borné comme suit: vers le sud-est par le chemin public ou route No 41; en arrière vers le nord-ouest par autre partie du lot No 164 dudit cadastre demeurant la propriété de la venderesse (St-Jérôme Properties Inc.); d'un côté vers le nord-est par l'emplacement appartenant à Dame Madeleine Chancberg-Zap et de l'autre côté vers le sud-ouest par l'emplacement appartenant à Dame Ida Weinstein-Yaphe.Wald, M.-Mr.Edward.P.163.Partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro cent soixante-trois (P.163), mesurant cent neuf pieds (109') de largeur en front le long du chemin public et semblable largeur en arrière; sur cent pieds (100') de profondeur dans ses lignes latérales nord-est et sud-ouest, mesure anglaise et plus ou moins; borné comme suit: en front vers le sud-est par le chemin public ou route No 41; d'un côté vers le nord-est par l'emplacement appartenant à M.Charles Cohen; de l'autre côté vers le sud-ouest par l'emplacement de Dame Gabrielle Moquette-Pilot et en arrière vers le nord-ouest par autre partie du lot No 163 demeurant la propriété de la venderesse (St-Jérôme Properties Inc.) .$ 26.24 S 49.04 S 75.28 Part of the lot of land known and designated under number one hundred and sixty-four (P.164) measuring one hundred and fifteen feet (116') in width by one hundred feet (100') in depth.English measure and more or less, bounded as follows: on the southeast by the public road or Highway No.41; in the rear on the northwest by another part of lot No.164 of the said cadastre remaining the property of the vendor (St-Jérôme Properties Inc.) ; on one side on the northeast by the emplacement belonging to Mrs.Madeleine Chancberg-Zap and on the other side on the southwest by the emplacement belonging to Mrs.Ida Weinstein-Yaphe.24.30 47.13 71.43 Part of the lot of land known and designated under number one hundred and sixty-three (P.163) measuring one hundred and nine feet (109') in width in front along the public road and the same width in the rear by one hundred feet (100') in depth on its lateral northeast and southwest lines, English measure and more or less, bounded as follows: in front on the southeast by the public road or Highway No.41; on one side on the northeast by the emplacement belonging to Mr.Charles Cohen, on the other side on the southwest by the emplacement of Mrs.Gabrielle Moquette-Pilot and in the rear on the northwest by another part of lot No.163 remaining the property of the vendor (St-Jérôme Properties Inc.).Zap, Mme-Mrs.Dauld.P.163.Partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro cent soixante-trois (P.163), mesurant cent vingt-deux pieds et trente-trois centièmes de pied (122.33') de largeur sur cent pieds (100') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins; borné comme suit : en front vers le sud-est par le chemin public ou route No 41; en arrière vers le nord-ouest par autre partie du lot No 163 demeurant la propriété de la venderesse (St-Jérôme Properties Inc.); d'un côté vers le nord-est par l'emplacement appartenant à Harry H.Elliott et de l'autre côté vers le sud-ouest par le lot No 164 dudit cadastre.Les lots ci-dessus font partie du cadastre officiel de la paroisse de St-Jérôme.26.24 51.37 77.61 Part of the lot of land known and designated under number one hundred and sixty-three (P.163) measuring one hundred and twenty-two and thirty-three hundredths feet (122.33') in width by one hundred feet (100') in depth, English measure and more or less, bounded as follows: in front on the southeast by the public road or Highway No.41; in the rear on the northwest by another part of lot No.163 remaining the property of the vendor (St-Jérôme Properties Inc.); on one side on the northeast by the emplacement belonging to Harry H.Elliott and on the other side on the southwest by lot No.164 of the said cadastre.The abovementioned lots are part of the official cadastre of the parish of St.Jérôme.Corporation municipale de la paroisse de Saint-Hippolyte Municipal corporation of the parish of Saint-Hippolyte Ste Marie des Laureatides.Partie 23B, Rang 1 Abercrombie.Borné en front vers le nord-est par le chemin public, vers le sud la paroisse de Ste-Sophie, nord-ouest lot 23 et contenant une superficie de deux arpents 94 centième.Partie du 23C Rang 1 Abercrombie.Borné en front au nord-ouest par le chemin public, au sud la paroisse de Ste-Sophie au sud-ouest par le lot 23B superficie 1 arpent 23 centièmes.Partie du 24B Rang 1 Abercrombie.Borné en front au nord-ouest par le chemin public au nord-est par un autre chemin public conduisant à Ste-Sophie au sud-est par la paroisse de Ste-Sophie et au sud-ouest par le lot 23C, superficie 1 arpent 61 centièmes.S 16.01 t 16.01 Part 23B, Range 1, Abercrombie.Bounded in front on the northeast by the public road, on the south by the parish of St.Sophie, northwest by lot 23, containing two and ninety-four hundredths arpents.Part of 23C, Range 1, Abercrombie.Bounded in front on the northwest by the public road, on the south by the parish of St.Sophie, on the southwest by lot 23B, containing 1 and 23 hundredths arpents.Part of 24B, Range 1, Abercrombie.Bounded in front on the northwest by the public road, on the northeast by another public road leading to St.Sophie, on the southeast by the parish of St.Sophie and on the southwest by lot 23C.containing 1 and 61 hundredths arpents. 818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Noms Lots et cad.Names Lots and cad.Lafrance.Dame Madelaine Pelletier et-and Lafrance, Claude.Partie du 20C, Rang 2 Abercrombie.Mesurant 100 pieds par 89 pieds, borné en front nord-est par un rue partie du 20C, au nord-ouest par une autre rue de 40 pieds (20C) au sud-est et en arrière au sud-ouest par le résidu du 20C avec bâtisse.Larouche, Gilles.Partie du lot 2SA Rang 3, Abercrombie, non subdivisé de figure triangulaire, mesurant 1 pied de largeur en front sur le chemin public, 58 pieds de largeur en arrière par une profondeur de 284 pieds dans la ligne côté ouest, borné en front au sud par ledit chemin public.En arrière au nord par le terrain appartenant à Albert Ward ou représentant.D'un côté à l'est par le résidu dudit lot originaire du 28A appartenant au vendeur et à l'ouest par un chemin privé appartenant à J.E.Deschénes ou représentant.- Monette, Claude.Lot 24B subdivision 69, Rang 3, Abercrombie.Lot 24B subdivision 20, Rang 3 Abercrombie.Partie 24B.Avec bâtisses.Décarie, Mme-Mrs.Mireille Coupai____ Partie du lot 23, rang 4, Abercrombie.Borné en avant à l'est par le Lac des 14 Iles, en arrière à l'ouest par un chemin partie du même lot, au nord et au sud mesurant 100 pieds de largeur dans ses lignes est et ouest et de 200 pieds en profondeur nord et sud, à prendre ledit emplacement à une distance de 10 pieds de l'emplacement de Cuté Bouhier, jusqu'à en profondeur de 50 pieds et ensuite distancé de 20 pieds de l'emplacement de J.B.Charbonneau.Avec bâtisse.Modler, Leslie.Lot 25, subdivision 11, rang 6, Abercrombie.Rétrocession Leslie Modler, avec bâtisse.Charpentier, Fernand.Partie du lot 20B, rang 8, Kilkenny.100 pieds de largeur dans sa ligne nord-ouest et sud-ouest, en profondeur, 80 pieds dans sa ligne nord-est et sud-ouest.Borné en front au sud-est par une rue projetée de 40 pieds de largeur, au sud-ouest par le lot 28B-44, nord-est par le résidu du lot 28B, rang 8, Kilkenny, avec bâtisse.Pearson, Gordon J.Une partie du lot 29A, rang 8, Kilkenny.140 pieds de largeur sur cent quatre-vingts pieds (180').bornée sur la façade par leB terrains de P.J.Maher & al ou représentants.En arrière par le terrain de Anthime Sigouin, père, le vendeur précédent ou représentants.D'un côté vers le nord-est par le morceau de terrain appartenant à M.Holst ou représentants, et de l'autre côté vers le sud-ouest par un chemin de passage de douze pieds de largeur formant partie du même lot et appartenant au vendeur précédent ou représentants.Benoit, Aima.Partie du 29A, rang 8, Kilkenny, mesurant 100 x 100.Borné au nord par un chemin privé d'environ 15 pieds de largeur et autre côté par Anthime Sigouin.Buller, Paul.Lot 23B, subdivision 63, rang 8, Kilkenny.Noreau, Gaston.Partie du lot 24B, rang 10, Kilkenny.En front au sud d'un chemin qui est situé au sud du Lac Achigan connu et Taxes Taxes Rang munie.scol.Total Range Munie.School taxes taxes S 120.93 S 120.93 Part of 20C, Range 2.Abercrombie.Measuring 100 feet by 89 feet, bounded in front on the northeast by a street, part of 20C, on the northwest by another street of 40 feet (20C), on the southeast and in the rear on the southwest by the remainder of 20C with a building.18.16 18.16 Part of lot 28A, Range 3.Abercrombie, non subdivided, of a triangular configuration, measuring 1 foot in width in front on the public road, 58 feet in width in the rear by a depth of 284 feet on the line on the west side, bouuded iu front ou the south by the said public road.In the rear on the north by the land belonging to Albert Ward or representative.On one side on the east by the remainder of said original lot of 28A belonging to the vendor and on the west by a private road belonging to J.E.Deschênes or representative.499.20 499.20 Lot 24B, subdivision 69, Range 3, Abercrombie.Lot 24B.subdivision 20, Range 3, Abercrombie.Part 24B.With buildings.318.29 318.29 Part of lot 23, Range 4, Abercrombie.Bounded in front on the east by Lac des 14 Iles, in the rear on the west by a road forming part of the same lot, on the north and south measuring 100 feet in width on its east and west lines and 200 feet in depth north and south, the said emplacement to be taken at a distance of 10 feet from the emplacement of Cuté Bouhier to a depth of 50 feet, then 20 feet from the emplacement of J.B.Carbonneau.With a building.191.48 $ 116.45 307.93 Lot 26, subdivision 11, Range 6, Abercrombie.Retrocession Leslie Modler with building.170.26 170.26 Part of lot 20B, Range 8, Kilkenny.100 feet in width on its northwest and southwest lines, SO feet in depth on its northeast and southwest lines.Bounded in front on the southeast by a planned street 40 feet wide, on the southwest by lot 28B-44 and on the northeast by the remainder of lot 28B, Range 8, Kilkenny.With Building.71.63 284.40 355.93 Part of lot 29A, Range 8 Kilkenny.140 feet in width by one hundred and eighty feet (180') bounded in front by the lands of P.J.Maher ft al or representatives.In rear by the land of Anthime Sigouin, Sr, the auteur of the vendor or representatives.On one side toward the northeast by the piece of land belonging to Mr.Hoist or representatives, and another side toward the southwest by a passage way of twelve feet in width forming part of the same lot and belonging to the auteur of the vendor or representatives.11.97 11.97 Part of 29A, Range 8, Kilkenny, measuring 100 x 100.Bounded on the north by a private road of about 15 feet in width and on the other side by Anthime Sigouin.8.31 8.31 Lot 23B, subdivision 63, Range 8, Kilkenny.168.16 168.16 Part of lot 24B, Range 10, Kilkenny.In front on the south by a road which is situted south of Achigan Lake, this lot QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.k 819 Taxes Taxes Noms Lots et cad.Hang munie.scol.Total Names Lots and cad.Range Munie.School taxeB taxes désigné, ce lopin de terre comme faisant partie du lot 24B, rang 10K, mesurant 80 pieds sur le chemin par 180 pieds de profondeur, borné en front par le chemin, en arrière au sud et d'un côté par le vendeur Paul Ménard et l'autre côté par le terrain de Omer Perrault, avec bâtisse.Page, René.Partie du lot 21, rang 10, Kilkenny.Lequel emplacement mesurant 50 pieds de largeur sur l'avenue Marcel et 125 pieds de profondeur.Borné au sud par l'avenue Marcel et des trois autres côtés par partie du même lot, propriété du vendeur, N.Beauchamp, avec bâtisse.Beauchamp, Jean.Partie du lot 21, rang 10, Kilkenny.Mesurant 100 pieds de largeur dans sa ligne sud.150 pieds dans sa ligne nord, 100 pieds dans sa ligne ouest, 97 pieds dans sa ligne est ou sud-est.En front vers le sud, partie du lot 21, vers l'est ou sud-est par Thomas Beauchamp, en arrière nord et ouest partie du lot 21.Lot 21, 50 pieds de largeur en front par le chemin public sur 100 pieds de profondeur.Borné en front par le chemin public sur 100 pieds au sud, à l'est par l'acquéreur, en arrière nord et ouest par le résidu du lot 21.Lot 21, 100 pieds au nord et sud et 100 pieds est et ouest.Borné au sud par le chemin public, en arrière nord partie du lot 21, côté est par Thomas Beauchamp, à l'ouest par Alban Leduc, avec bâtisses.Legault, André & David.Lot 22B, subdivision 18, range 10, Kilkenny, avec bâtisse.Legault, André.Lot 22B, subdivision 10, Kilkenny, avec bâtisse.Barnett, Mme-Mrs.Granada Rodriguez Partie du lot 20, rang 11, Kilkenny.Ayant façade sur le chemin Masson, mesurant 100 pieds en avant, 100 pieds à l'arrière sur 405 pieds de profondeur, bornée en avant à l'est par le chemin Masson et d'un côté au sud par la ligne separative, entre les dixième et onzième rang, ou par un emplacement appartenant à J.Arthur Boivin ou représentants et de l'autre côté au nord et à l'arrière à l'ouest par le résidu dudit numéro 20, appartenant à Thomas Beauchamp.Ménard.Gilles.Lot 19B, subdivision 6, rang 11, Kilkenny.Bérubé, MUe-Miss Jeannette.Partie 3 et 4, rang 1, Wexford.53 arpents 49 centièmes, plan et description technique.Mercure, Claude, syndic-trustee.Partie 3 et 4, rang 1, Wexford.Mesurant 150 pieds en largeur et 200 en profondeur, borné en front sud-ouest par Montée St-Hippolyte, en arrière nord-est et d'un côté nord-ouest par d'autres parties du lot appartenant à Henri Gohier et de l'autre côté sud-est et partie de lot appartenant à Ovila Gauthier et Henri Gohier.Chappel, Clifford.Partie du lot 24A, rang 9, Kilkenny.Mesurant 100 pieds au nord-ouest au long du lac Achigan sur 203 pieds au nord-est, 100 pieds en arrière au sud-est et 200 pieds au sud-ouest, située à environ 100 pieds du point ouest de référence, située à ('.intersection des lignes nord-est et nord-ouest de la propriété de Robert Reilly, et indiquée sur le plan ci-après référé.of land is known and designated as forming a strip of land which is part of lot 24B.Range 10K, measuring 80 feet on the road by 180 feet in depth, bounded in front by the road, in the rear on the south and on one side by the vendor, Paul Ménard, and on the other side by the land of Orner Perrault, with building.S 102.64 $ 102.64 Part of lot 21, Range 10, Kilkenny.The said emplacement measures 60 feet in width on Marcel Avenue and 125 feet in depth.Bounded on the south by Marcel Avenue and on the other three sides by part of the same lot, property of the vendor, N.Beauchamp, with building.304.62 304.62 Part of lot 21, Range 10, Kilkenny.Measuring 100 feet in width on its south line, 150 feet on its north line, 100 feet on its west line, 97 feet on its east or southeast line.In front on the south partly by lot 21, on the east or southeast by Thomas Beauchamp, in the rear on the north and west partly by lot 21.Lot 21, 50 feet in width in front by the public road and 100 feet in depth.Bounded in front by the public road, 100 feet on the south, on the east by the purchaser, in the rear on the north and west by the remainder of lot 21.Lot 21, 100 feet on the north and south and 100 feet on the east and west.Bounded on the south by the public road, in the rear on the north partly by lot 21, on the east side by Thomas Beauchamp, on the west by Alban Leduc.With buildings.145.89 145.89 Lot 22B, subdivision 18, Range 10, Kilkenny.With buildings.172.70 172.70 Lot 22B, subdivision 10, Kilkenny.With buildings.25.99 25.99 Part of lot 20, Range 11 Kilkenny.Fronting on Masson Road, measuring 100 feet in front, 100 feet in rear by 405 feet in depth, bounded in front to the east by Masson Road and one side to the south by the division line, between the tenth and the eleventh range, or by an emplacement belonging to J.Arthur Boivin or representatives and another side to the north and in rear to the west the residue of the said number 20, belonging to Thomas Beauchamp.13.19 13.18 Lot 19B, subdivision 6, Range 11, Kilkenny.27.20 27.20 Parts 3 and 4, Range 1, Wexford.53 and 49 hundredths arpents, technical plan and description.13.19 13.19 Parts 3 and 4, Range 1, Wexford.Measuring 150 feet in width and 200 feet in depth, bounded in front on the southwest by Montée St-Hippolyte, in the rear on the northeast and on one side on the northwest by other parts of the lot belonging to Henri Gohier and on the other side on the southeast partly by the lot belonging to Ovila Gauthier and Henri Gohier.74.11 74.11 Part of lot 24A, Range 9 Kilkenny.Measuring 100 feet northwest on the Lake Achigan by 203 feet northeast, 100 feet in rear southeast and 200 feet southwest, situated at 100 feet approximatively from reference point west, situate at the intersection of the northwesterly and northeasterly lines of the property of Robert Reilly, and shown on the plan herein 820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101,' année, n° 4 Noms Names Lots et cad.Lots and ead.Taxes Rang munie.Range Munie.taxes Taxes scol.School taxes Total Ladite partie bornée au nord-ouest par ledit lac Achigan, au nord-est au sud-est et au sud-ouest par d'autres parties dudit lot 24A dudit cadastre.Clément, Robert.Lot 5A, subdivision 29, rang 2, Wexford, avec bâtisse.Adam, Mme-Mrs.Marie-Louise.Lot 10.subdivision 117.rang 2, Wexford.Lot, 10 subdivision 147, rang 2 Wexford.Boensel, Herbert.Lot 10, subdivision 97, rang 2, Wexford.Emmer, Mile-Miss Emilia &al.Lot 10, subdivision 96, rang 2, Wexford.Lot, 10 subdivision 130, rang 2 Wexford.Katterloher, Herman.Lot 10, subdivision 69, rang 2, Wexford.Laberge, Marcel.Lot 10, subdivision 49, rang 2, Wexford.Paquette, Guy &al.Lot 10, subdivision 154, rang 2, Wexford.Renaud, Robert.Lot 10, subdivision 136, rang 2, Wexford.Charles De Gagné.P.14 - P.15.rang 2, Wexford.1° 4 à 5 arpents du grand chemin, jusqu'au cordon finissant en pointe, à forme de triangle dont un côté situé dans la ligne de chemin entre le lot 13 et 14 du même rang, mesurant à peu près 2}£ arpents de profond.2° Un morceau dans le rang 2, Wexford, désigné sous le No de lot P.13, \u2022 e arpents de long par e arpents de long par 2 arpents de profond », borné par la ligne de division entre le 2e et 3e Rang Wexford, à l'est par le lot 14 du 2e Rang Wexford, au nordet à l'ouest par le résidu du lot 13 appartenant à M.Philibert Lamoureux.3° Un terrain situé au Lac en Coeur, faisant partie du lot 14 du 1er Rang Wexford, 100 x 100 borné parle Lac en Coeur de tous les côtés par le résidu du lot 14, avec bâtisses, moins parties vendues.after referred to bounded said part to the northwest by said Lake Achigan to the northeast to the southeast and the southwest by other parts of said lot 24A of said cadastre.S 139.80 S 139.80 Lot 6A, subdivision 29, Range 2, Wexford.With buildings.20.71 Lot 10, subdivision 117, Range 2, Wexford.Lot 10, subdivision 147, Range 2.Wexford.11.97 Lot 10, subdivision 97, Range 2, Wexford.25.37 45.44 Lot 10, subdivision 96, Range 2, Wexford.Lot 10, subdivision 130, Range 2, Wexford.19.25 Lot 10, subdivision 69, Range 2, Wexford.17.64 Lot 10, subdivision 49, Range 2, Wexford.24.85 Lot 10, subdivision 154, Range 2, Wexford.113'.54 Lot 10, subdivision 136, Range 2, Wexford.20.71 11.97 70.81 19.26 17.64 24.85 113.64 1,743.16 1,743.16 P.14 - P.15, Range 2, Wexford.1.4 to 5 arpents from the main road to the cordon finishing in a point, a triangular configuration a side of which is situated on the road line'between lots 13 and 14 of the same range, measuring about 2k arpents in depth.2.A piece of land on Range 2.Wexford, designated under the No.of lot P.13, \"e arpents de long par e arpents de long par 2 arpents de profond\", bounded by the line of separation between the 2nd and 3rd Range of Wexford, on the east by lot 14 of the 2nd Range of Wexford, on the north and west by the remainder of lot 13 belonging to Mr.Philibert Lamoureux.3.A piece of land situated at Lac en Coeur forming part of lot 14 of the 1st Range of Wexford, 100 x 100 bounded by Lac en Coeur, on all sides by the remainder of lot 14, with buildings, less the parts sold.Municipalité du village de Prévost \u2014 Municipality of the village of Prévost Slodovnick, succ.-est.Benny, P.363 & P.365.Goldberg, succ.-est.Jenny.Les emplacements situés à Prévost, comté de Terrebonne, connus et désignés comme étant partie des lots 365 et 363 du livre de renvoi officiel de la Paroisse de St-Jérôme tels qu'acquis par Jenny Goldberg et Benny Slodovnick par les actes numéros 106670 et 108183 et 117117 avec droit d'eau sur le lot 367.A distraire la partie réservée par le vendeur dans l'acte 106670.A distraire la partie vendue par l'acte 176892 à H.Covens.A distraire la partie vendue par l'acte 191828 à la Corporation de Shawbridge.* 276.37 S 374.17 $ 649.54 The emplacements situated at Prévost, County of Terrebonne, known and designated as being part of lots 366 and 363 of the official book of reference of the parish of St.Jérôme as purchased by Jenny Goldberg and Bennv Slodovnick by deeds numbered 106670 and 108183 and 117117 with water rights on lot 367.Save and to withdraw the part reserved by the vendor in deed 106670.Save and to withdraw the part sold by deed 175892 to H.Covens.Save and to withdraw the part sold by deed 191828 to the Corporation of Shawbridge. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 821 \t\t\tTaxes\tTaxes \t\tTaxes\tscol.\tscol.Noma\tLots et cad.\tmunie.\tcath.\tprot.Names\tLots and cad.\tMunie.\tCath.\tProt.\t\ttaxes\tschool\tschool \t\t\ttaxes\ttaxes Total Albert Wexler & al.P.94-20.Un emplacement situé à Prévost, connu et désigné comme étant le lot 94-20 du livre de renvoi officiel de la Paroisse de St-Sauveur, borné à l'ouest en front par la rue Lachance, au nord par le lot 94-21, à l'est par le lot 94-54 et au sud par le lot 94-18, mesurant 53 pieds de largeur par une profondeur de 52 pieds, avec bâtisse, contenant une superficie approximative de 2,756 pieds, mesure anglaise.$ 80.71 S 80.71 An emplacement situated at Prévost, known and designated as being lot 94-20 in the official book of reference of the parish of St.Sauveur, bounded on the west in front by Lachance Street, on the north by lot 94-21, on the east by lot 94-64 and on the south by lot 94-18, measuring 53 feet in width by a depth of 52 feet, with buildings, containing about 2,766 feet in area, English measure.Municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs Municipality of the parish of Sainte-Anne-des-Lacs Labrêche, Eugène.P.106-pt-1- Partie 106-ptie, 1, du cadastre officiel de la paroisse de St-Sauveur mesurant 828.8', 641.8', 600.6', mesurant en superficie quatre et cinq dixièmes arpents carrés et bornée par le chemin public.Montée Fournelle, par monsieur Réol Clouette, par le chemin Filion, avec toutes les bâtisses.S 200.00 8 743.44 S 943.44 Part 106-part 1 of the official cadastre of the parish of St.Sauveur measuring 828.8', 641.8', 500.6', containing four and five tenths square arpents in area and boundeb by the public road, Montée Fournelle, by Mr.Real Clouette, by Fillion Road, with all buildings.Municipalité de Piedmont \u2014 Municipality of Piedmont Dupuis.Gilles.P.31.Borné par chemin privé, par Joseph Beaulieu au s.e., et au s.o.par Gélestin Gervaie ou représentant.$ 26.06 8 27.69 8 53.74 Bounded by a private road, by Joseph Beaulieu on the southeast and on the southwest by Célestin Gervais or representative.Herrala, Teuvo.P.25, P.26.Borné par chemin public par C.H.Trottier, par C.P.R.$ 334.23 334.23 Bounded by the public road, by C.H.Trottier, by the C.P.R.Kertzer.Bernard.P.63.Borné par la ligne de division des lots 53 et 54, par Anthime Charbonneau, par F.S.Lewin par Paul Dubois.332.95 332.96 Bounded by the separating line of lots 53 and 54, by Anthime Charbonneau, by F.S.Lewin, by Paul Dubois.Kiopini.Jean.P.53.Borné par chemin privé au sud, sur le nord, à l'est et à l'ouest par d'autres parties du lot no 53.328.88 328.88 Bounded by the private road on the south, on the north, east and west by other parts of lot No.53.Raymond.Guy.P.31.Borné par un droit de passage, par C.Gervais ou représentant, par M.Filion.par W.J.Flymm.11.05 32.43 43.48 Bounded by a right of way, by C.Gervais or representative, by M.Filion, by W.J.Flymm.Société Bernel.62-53.Starey.Milade.P.41.Borné s.o.par chemin public, arrière par lot 41-p appartenant à T.Charbonneau.n.o.par p-41 appartenant à J.Smith se.par p-41 appartenant à P.W.Morin.P-41, est par chemin privé, s.o.par p-41 appartenant à P.W.Morin, par J.Smith.Les lota ci-dessus font partie du cadastre officiel de la Paroisse de St-Sauveur.2,158.93 3,407.14 5,566.07 .540.13 433.08 973.21 Bounded on the southwest by the public road, in the rear by lot 41-p.belonging to T.Charbonneau, on the northwest by p.41 belonging to J.Smith; southeast by p-41 belonging to P.W.Morin.P.41, east by a private road, southwest by P.41 belonging to P.W.Morin, by J.Smith.The abovementioned lots are part of the official cadastre of the parish of St.Sauveur. 822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101' année, n\" A Municipalité du village de Saint-Sauveur-des-Monts \u2014 Municipality of the village of Saint-Sauveur-des-Monts Taxes Taxes Noms Lots et cad.Rang munie.scol.Total Names Lots and cad.Range Munie.School taxes taxes Allard.Mme-Mrs.Gisèle.336-68,336-5-1,336-5-3.S 617.69 S 167.90 S 686.49 Allard, Raymond.336-5-7,335-5-9,335-5-11, 596.94 296.04 891.98 335-5-13.Barbeau, André.P.340-182.231.60 231.50 Borné en front par la rue Monette, à l'arrière par une partie Bounded in front by Monette Street, in the rear by a part of du lot 340-182 appartenant à la Suce.R.David, au nord-ouest lot 340-182 belonging to the R.David Estate, on the northwest par le lot 340-183 et au sud-est par le lot 340-181.by lot 340-183 and on the southeast by lot 240-181.Desiardins.Mme-Mrs.Aline (Smith).\t338-24.\t\t128.70\t128.70 Desroches, André.\t\t66.61\t45.95\t111.56 Joannette, Mme-Mrs.Yvette.\t339-51.\t565.72\t\t665.72 \t338-64,338-66.\t429.90\t346.06\t775.96 Lefebvre, Mme-Mrs.Huguette Dulude .\t338-49.\t\t29.30\t29.30 St-André Yvan.\t396-35.\t211.32\t121.66\t332.88 Wilde Donald.\t350-46.360-47,360-48.\t468.70\t411.02\tS79.72 Corporation municipale de la paroisse de Saint-Sauveur \u2014 Municipal Corporation of the parish of Saint-Sauveur Mme-Mrs.Suzanne Fortier.épouse de P.318.wife of R.Thériault.Cadastre de la paroisse de St-Sauveur, mesurant sur la Montée Jeannine 200 pieds de largeur, en arrière 100 pieds de largeur; 150 pieds dans sa ligne sud-est; 180 pieds dans l'autre ligne; bornée vers le sud-est par la ligne de division des lots 318 et 276 Côte St-Lambert Sud; en front au sud-ouest par Montée Jeannine; au nord-est et au nord-ouest par d'autres parties du lot No 318.Dame Suzanne Fortier, épouse de-wife of P.298.Ralph Thériault.Cadastre de la paroisse de St-Sauveur, mesurant 200 pieds par 165 pieds; bornée par un chemin de 30 projetée; par Dame G.Colonello; par Mme J.Lauzon-Jalbert; par un chemin privé de 40'.Dame Françoise Lamarche, épouse de- P.464.wife of Roger DeQuoy.Cadastre de la paroisse de St-Sauveur, mesurant 150.8 pieds dans sa ligne nord-ouest; 150 pieds dans sa ligne sud-est; 199.5 pieds dans sa ligne sud-ouest; 211-5 pieds dans sa ligne nord-est; borné vers le nord-ouest par le chemin public; vers le sud-ouest par une partie du 464 propriété de Louis Philiore; vers le sud-est par partie du 464, propriété de Anita Bois-vert; vers le nord-est par parties du 464, appartenant à Mme Jacques DeQuoy et Anita Boisvert.Ce lot est connu comme étant 464-4 sur un plan No 2615, F.Bourassa, arpenteur-géomètre.Maurice Dessureault.476-69, 476-70.Cadastre de la paroisse de St-Sauveur.Roland Filion.327-14.Cadastre de la paroisse de St-Sauveur, avec bâtisse.Mme-Mrs.Huguette D.Lefebvre.301-34.Cadastre de la paroisse de St-Sauveur, avec bâtisse.Mme-Mrs.Roger Matte.476-75, 476-76.Cadastre de la paroisse de St-Sauveur.Hawco Construction Ltd.P.251.Cadastre de la paroisse de St-Sauveur, mesurant 526 pieds de largeur dans ses lignes nord-est et sud-ouest, sur 325 pieds dans ses lignes, nord-ouest et Bud-est: bornée vers le nord-est 8.73 S 16.75 S 24.48 Cadastre of the Parish of St.Sauveur measuring 200 feet in width on Montée Jeannine, in the rear 100 feet in width, 150 feet on its southeast line, 180 feet on the other line, bounded on the southeast by the separating line of lots 318 and 276 Côte St.Lambert South; in front on the southwest by Montée Jeannine, on the northeast and northwest by other parts of lot No.318.26.80 43.75 70.55 Cadastre of the Parish, of St.Sauveur measuring 200 feet by 165 feet, bounded by a planned road of 30', by Mrs.G.Colonello, by Mrs.J.Lauzon-Jalbert, by a private road of 40'.30.46 54.60 85.06 Cadastre of the Parish of St.Sauveur measuring 150.8 feet on its northwest line, 150 feet on its southeast line, 199.5 feet on its southwest line, 211.5 feet on its northeast line, bounded on the northwest by the public road, on the southwest by a part of 464 property of Louis Philiore; on the southeast by part of 464 property of Anita Boisvert, on the northeast by parts of 464 belonging to Mrs.Jacques DeQuoy and Anita Boisvert This lot is known as being 464-4 on plan No.2615, F.Bourassa, land-surveyor.26.32 45.16 Cadastre of the Parish of St Sauveur.71.48 .93.32 313.26 406.68 Cadastre of the Parish of St.Sauveur, with building.154.21 114.46 268.66 Cadastre of the Parish of St.Sauveur, with building.6.44 9.78 Cadastre of the Parish of St.Sauveur.16.22 .2,064.06 2,147.85 4,211.91 Cadastre of the Parish of St.Sauveur measuring 525 feet in width on its northeast and southweBt lines by 325 feet on its northwest and southeast lines, bounded on the northeast QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.k 823 Taxes Taxes Noms Lots et cad.Rang munie.scol.Total Names Lots and cad.Range Munie.School taxes taxes par P.250; et de tous les autres côtés par partie 251, appartenant à V.Nymark.La ligne nord-ouest est parallèle à et située à 780 pieds au sud-est de la ligne sud-est du chemin public, sujet à un droit de passage de 14 pieds de profondeur par toute la largeur du lot touchant au lot No 250.Avec lodge, piscine, terrain de tennis, cottage et motel.Dame Denise Bourget, épouse de-wife of P.466.Yves Levesques.Cadastre de la paroisse de St-Sauveur, partant d'un point situé sur la ligne de division des lots Nos 466 et 467 à une distance de 125 pieds de la rive du Lac des Chats; de là allant dans une direction ouest sur une distance de 105 pieds longeant ainsi la ligne de division des lots 466 et 467; de là tournant vers la droite et se dirigeant vers le nord sur une distance 219.9 pieds longeant ainsi une vieille clôture jusqu'à un point situé sur le côté nord d'un chemin privé \u2014 cette ligne étant bornée sur une autre partie dudit lot No 466, propriété de Mlle A.Boisvert; de là tournant vers la droite et longeant les contours du ruisseau sur une distance d'environ 305 pieds jusqu'à la rive du Lac des Chats; de là tournant vers la droite et longeant la rive dudit lac sur une distance de 45 pieds jusqu'à la rive nord de la propriété de M.R.Taché; de là tournant vers la droite et se dirigeant vers l'est sur une distance de 160 pieds longeant ainsi la ligne nord de la propriété de R.Taché; de là tournant vers la gauche et longeant la ligne nord-ouest des propriétés respectives de M.R.Taché et F.G.Michalak et J.Cardella jusqu'au point de départ, avec bâtisse.by part 250 and on all other sides by part 251 belonging to V Nymark.The northwest line is parallel to and situated at 780 feet southeast of the southeast line of the public road, subject to a right of way of 14 feet in depth by the whole width of the lot touching lot No.250.With a lodge, swimming pool, tennis court, cottage and motel.S 62.54 $ 69.86 S 112.40 Cadastre of the Parish of St.Sauveur Starting at a point situated on the separating line of lots Nos 466 and 467, 125 feet from the shore of Lac des Chats; thence, westerly 105 feet along the separating line of lots 466 and 467; thence, on the right northerly 219.9 feet along the old fence to a point situated on the north side of a private road \u2014 this line bounded by another part of said lot No.466 belonging to Miss A.Boisvert; thence, to the right along the contours of the stream about 305 feet to the shore of Lac des Chats; thence, to the right and along the shore of the said Lake, 45 feet to the north shore of the property of Mr R.Taché; thence, to the right and easterly 160 feet along the north line of the property of R.Taché; thence, to the left and along the northwest line of the respective properties of Mr.R.Taché and F.G.Michalak and J.Cardella to the starting point.With building.Thérèse Lussier.P.509.Cadastre de la paroisse de St-Sauveur, mesurant 150 pieds dans ses lignes nord-ouest et sud-est, par 300 pieds dans ses lignes nord-est et sud-ouest, avec bâtisse.Le ruisseau traversant ledit immeuble traverse la ligne de division des lots 509 et 510 qui est la ligne nord-est de l'immeuble et est exactement au centre de cette ligne.Cet immeuble est borné vers le nord-est par le lot No 510, vers le nord-ouest, le sud-ouest et le sud-est par d'autres parties du lot No 509.Leslie Meade.P.448.Le cadastre de la paroisse de St-Sauveur, mesurant 1 arpent dans ses lignes nord-est et sud-ouest sur H arpent dans ses lignes nord-ouest et sud-est, mesure française, sans bâtisse; borné vers le sud-est par la ligne de division des lots 448 et 325; vers le sud-ouest par partie du 448, propriété de Malcolm Monk ou représentants; vers le nord-ouest par une partie du 448, et vers le nord-est par partie 447.Dame Lise Trempe, épouse de-wife of P.445.Jean-Claude Pecquet.Le cadastre de la paroisse de St-Sauveur, mesurant 150 pieds dans ses lignes sud et nord, et 106 pieds dans ses lignes nord-est et sud-ouest; borné au nord, nord-est, sud, sud-ouest par d'autres parties du lot 445.Le point A est situé à 25.8 pieds du point E qui est la ligne de division entre les lots Nos 445 et 446.Le point E est situé à 60 pieds du point F qui est la ligne de la rue (rue 445-1).Cette lisière de terrain de forme parallel ogr a m mique est indiquée par les « A-B-C-D-A » et par un liséré rouge sur un plan préparé par Hubert Murray, arp.-géomètre en date du 28 septembre 1966.109.90 109.90 Cadastre of the Parish of St.Sauveur measuring 150 feet on its northwest and southeast lines by 300 feet on its northeast and southwest lines, with a building, The stream crossing the said immoveable crosses the separating line of lots 509 and 510 which is the northeast line of the immoveable and is exactly at the centre of this line.This immoveable is bounded on the northeast by lot No.510, on the northwest, southwest and southeast by other parts of lot No.509.26.33 12.78 39.11 Cadastre of the Parish of St.Sauveur measuring 1 arpent on its northeast and southwest lines by arpent on its northwest and southeast lines, French measure, without buildings; bounded on the southeast by the separating line of lots 448 and 325; on the southwest by part of 448 belonging to Malcolm Monk or representatives; on the northwest by a part of lot 448 and on the northeast by part 447.11.07 1680 27.87 Cadastre of the Parish of St.Sauveur measuring 150 feet on its south and north lines and 106 feet on its northeast and southwest lines; bounded on the north, northeast, south, southwest by other parts of lot 445.Point A is situated 25.8 feet from Point E which is the line of separation between lots Nos 445 and 446.Point E is situated 60 feet from Point F which is the line of the street (street 445-1).This strip of land of a parallelogrammic configuration is indicated by \"A-B-C-D-A\" and by a red line on a plan executed by Hubert Murray, land-surveyor, on September 28, 1966.Rousso Estate.411.77 791.43 1,203.20 Lots, cad \u2014488-3.7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 489-2, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44,492-1,2.5.9, 17, 18, 19.21,22,23, 24,25, 26, 32,35.36, 38,39,40, 43, 44.45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.Cadastre de la paroisse de St-Sauveur, Cadastre of the Parish of St.Sauveur.Parties 488, 489 et 492 du cadastre de la paroisse de St- Parts 488, 489 and 492 of the cadastre of the Parish of Sauveur, moine les lots cadastrés et les lots vendus.St.Sauveur, less and to withdraw the cadastral and sold lots.Dame Joan Benson, épouse de-wife of Cert Nickelsen.P.311.13.60 22.37 36.87 824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Taxes Taxes Noms Lots et cad.Rang munie.scol.Total Names Lots and cad.Range Munie.School taxes taxes Le cadastre de la paroisse de St-Sauveur, mesurant 135 pieds dans sa ligne sud-est; cent pieds dans sa ligne sud-ouest; 78 pieds dans sa ligne nord-ouest; borné vers le nord-est par le Lac Prévost; vers le sud-est par P.311, appartenant à Pouet-chine; vers le sud-ouest et le nord-ouest par parties 311, propriété de Maurice Richard.Cadastre of the Parish of St.Sauveur measuring 135 feet on its southeast line, one hundred feet on its southwest line, 78 feet on its northwest line; bounded on the northeast by Prévost Lake; on the southeast by part 311 belonging to Poustchine.on the southwest and northwest by parts 311 belonging to Maurice Richard.Municipalité de Mont-Rolland \u2014 Municipality of Mont-Rolland Maillé Esdras, a/a-c/o Notaire Gaétan P.4, P.3.4.$ 263.50 S 456.99 * 720.49 Ruel.Paillé, Mile-Miss Gilberts.6-7 .3 .61.02 139.8U 200.92 Rousseau.Mme-Mrs.Nicole Beau- P.8 .3 .67.86 67.86 champs.Mc Nellen Trevors, a/s-c/o A.Willis- P.7.P.8.3.200.78 411.43 612.21 Les lots ci-dessus sont situés dans le canton Wexford, cadas- The abovementioned lots are situated in the Township of tre officiel de la paroisse de Ste-Adèle.Wexford, official cadastre of the Parish of St.Adèle.Municipalité de Sainte-Adèle \u2014 Municipality of Sainte-Adèle \t\t\tTaxes\tTaxes \t\tTaxes\tscol.\tscol.Noms\tLots et cad.\tmunie.\tcath.\tprot.Names\tLots and cad.\tMunie.\tCath.\tProt.\t\ttaxes\tschool\tschool \t\t\ttaxes\ttaxes Total Apreo, Vincent.P5B-IV Morin- Du 4e rang Morin, partie 5B, mesurant 95' par 190.8', bornée par le chemin public du 4e rang; par la ligne qui sépare ledit lot 5B du lot 6C; par Dame Claire Rolland-Langlois; par le vendeur.Enrg.#297068.Devon Agencies Limited.2A-285-XI Morin.Eumicke, Suzanne.P5-VII Wexford.Partie 5 du 7e rang Wexford, mesures techniques et bornée au sud par la ligne de division des lots 4 & 5; à l'est par la route publique Sainte-Adèle-Sainte-Marguerite; au N.E.par le 5-5 à L.Mendelson; au nord par une autre partie non subdivisée du lot 5 à L.Mendelson, W.Vangehassend, A.Drury et L.Larochelle et aux vendeurs; au N.O.par autre partie du lot 5 à J.Sauer; au nord par une autre partie du lot 5 à J.Sauer; à l'ouest par une partie du lot 5 à Josette Cochand-Chedel et aux vendeurs.Partie 5, mesures techniques et bornée au nord par un chemin privé; à l'est par une autre partie non subdivisée du lot 5 à M.Maguire, aux vendeurs et à E.Drody; au sud par la ligne de division des lots 4 et 5; à l'ouest par le lot 5-49.Partie 6, mesures techniques et bornée à l'ouest par les lots 6-7 et 6-30 à A.Reyburn; à l'ouest par le 6-31; au nord et au N.O.par le lot 6-8 et 6-32 à l'acquéreur; au S.O.par le lot 6-9 et au sud par le chemin public (6-29).Enrg.#362587.Frenette.Claude.P1A-II.Morin- P2A-II, Morin.1A-36-II, Morin.1A-37-II, Morin.1A-38-II, Morin.4B-2-X, Morin 4B-3-X, Morin.D'une partie du No 1A dans le deuxième rang Morin mesurant 160x200 et bornée par partie du No 1A, par le chemin .8 336.41 $ 336.41 From the 4th Range of Morin, part 5B measuring 95' x 190.8'.bounded by the public road of the 4th Range, By the line which separates said lot 5B from lot 5C, by Mrs.Claire Rolland-Langlois, by the vendor.Registration #297068.8 102.27 $ 131.36 2.16 235.77 .229.67 189.09 418.66 Part 6 of the 7th Range of Wexford, technical measures and bounded on the south by the separating line of lots 4 & 5, on the east by the St.Adèle-Sainte-Marguerite Public Highway, on the northeast by 5-5 belonging to L.Mendelson, on the north by another non subdivided part of lot 5 belonging to L.Mendelbon.W.Vangehassend, A Drury and L.Larochelle and vendors, on the northwest by another part of lot 5 belonging to J.Sauer, on the north by another part of lot 5 belonging to J.Sauer, on the west by a part of lot 5 belonging to Josette Cochand-Checel and vendors.Part 5, technical measures and bounded on the north by a private road, on the east by another non subdivided part of lot 5 belonging to Mr.Maguire, the vendors and E.Drody, on the south by the separating line of lots 4 and 5, on the west by lot 6-49.Part 6, technical measures and bounded on the west by lots 6-7 and 6-30 belonging to A.Reyburn, on the west by 6-31, on the north and northwest by lot 6-8 and 6-32 belonging to the purchaser, on the southwest by lot 6-9 and on the south by the public road (6-29).Registration #352587.362.26 428.22 790.48 A part of No.1A in the second range of Morin measuring 150 x 200 and bounded by part of No.1A, by the public QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.k S25 Taxes Taxea Taxes scol.scol.Noms Lots et cad.munie.cath.prot.Total Names Lots and cad.Munie.Cath.Prot.taxes school school taxes taxes public, par le 1A-55 et par une autre partie du No 1A; Une autre partie du No 1A ayant une superficie de 26,505 pieds carres, bornée en avant par une rue de 40', d'un côté vers le nord-est par le No 1A-53 et partie du No 1A-52 en arrière vers le sud et de l'autre côté au sud-ouest par autres parties du No 1A.Parties des nos 1A et 2A.ayant une superficie de 26,612 pieds carrés et bornées en avant par une rue projetée d'un côté vers l'est par le No 1A-49, en arrière et de l'autre côté par autres parties desdits Nos 1A et 2A; les Nos 1A-38, 37 et 36; du No 4B-2 dans le dixième rang Morin ainsi qu'une partie du No 4-R3.mesurant 40 pied* de largeur par 14.6 de profondeur dans la ligne sud-est et 10 pieds dans la ligne nord-ouest et borné en front vers l'est et le nord-est par le chemin public, en arrière par le No 1A-37, d'un côté vers le nord-ouest par le résidu dudit lot 4B-3 et de l'autre côté par le No 4B-2.Enregistrement #236836.road, by 1A-55 and by another part of No.1A.Another part of No.1A containing 26,505 square feet, bounded in front by a street of 40', on one side on the northeast by No.1A-53 and part of No.1A-52, in the rear on the south and on the other side on the southwest by other parts of No.1A.Parts of Nos 1A and 2A containing 26,512 square feet and bounded in front by a planned street, on one side on the east by No.1A-49, in the rear and on the other side by other parts of said Nos 1A and 2A; Nos 1A-38, 37 and 36 of No.4B-2 in the tenth range of Morin and a part of No.4B-3 measuring 40 feet in width by 14.6 feet in depth on the southeast line and 10 feet on the northwest line, bounded in front on the east and northeast by the public road, in the rear by No.1A-37, on one side on the northwest by the remainder of said lot 4B-3 and on the other side by No.4B-2.Registration #236836.Hamelin, Fernand & Cloutier, Richard.10I3-61-XI.Abercrombie.8 2,592.23 3 1,070.90 Hans, Peter.6-34-VII, Wexford.Hanson, Succ.-Estate Arthur.7-217 VI, Wexford.7-218 VI, Wexford.7-219 VI.Wexford.7-236/7-237/7-238/ Hicks.Leonard.P6-IV, Morin.De la partie du No 6 dans le 4e rang Morin, bornée vers le sud-est par la route numéro onze, vers le sud-ouest partiellement par la propriété de Roland Tremblay et partiellement par la propriété du vendeur, vers le nord-ouest par une route carrossable de quinze pieds de large sur la propriété du vendeur et vers le nord-est par la propriété du vendeur formant partie du même lot 6 enregistré #189085.82.63 265.91 S 3,063.13 149.64 265.91 .218.84 233.99 452.83 Part of No.6 in the 4th Range of Morin bounded towards the southeast by highway number eleven, towards the southwest partly by Laurent Tremblay's property and partly by the vendor's property, towards the northwest by a fifteen foot wide drive way on the vendor's property, and towards the northeast by the vendor's property forming part of the same lot 6.Enrg.# 189086.Leblanc.Yvette.P8A-IV, Morin- Partie 8A du 4e rang Morin, mesurant 50' sur 220\" et 180' et bornée par un chemin privé; par un ruisseau; par le vendeur; par un chemin privé, avec bâtisse, Enrg.#329724.94.77 9.87 104.64 Part 8A of the 4th Range of Morin measuring 50' x 220' and 180' bounded by a private road, by a stream, by the vendor, by a private road, with building.Registration #329724.La Maison Moderne Limitée.P9A-18/XI, Abercrombie.9A-8 /XI, Abercrombie.9A-5 /XI.Abercrombie.9A-6 /XI, Abercrombie.10A-19/IX.Abercrombie.9A-19-16P.Abercrombie.Delà plus grande partie du lot 9A-18 du Xle rang Abercrombie.bornée par la rue Morin: et dans une autre ligne S.E.par P.9A à A.Asselin; au N.E.partie par la rue Rolland et partie par le 9A-18-1: au N.E.par P.9A-18 à B.P.Forcier et G.Préfontaine; au N.O.par le 9A-18-1: au N.O.par P.9A-18 auxdits Forcier et Préfontaine; au N.O.par 9P.9A-18 à J-Robert Leblanc; au N.O.par le 9A-5.Le lot 9A-8.Le lot 9A-5.Tous les droits de la venderesse dans un droit de passage à pied sur un passage de 4' formant partie 9A-P.4 Le lot 9A-6.Le lot 10A-19.De la partie sud-est du lot 9A-19-partie 15 étant un passage en commun et bornée par le résidu dudit lot à Range Investments Limited; au N.E.par la limite N.E.dudit lot au 8.E.par le passage en commun (9A-5) ; au S.O.par la limite S.O.dudit lot.Avec bâtisses et ameublement.Enrg.#333193.19.639.06 16,614.44 204.84 36.468.34 Malcolm, Victor.P4B/X, Morin.Du Xe rang Morin, Partie 4B mesurant 240' par 200' et bornée par le grand chemin; au sud-est et nord-est par parties 4B; au nord-ouest par le lot 5.De partie 4B du 10e rang Morin.mesurant 200' par la moitié de la largeur dudit lot 4B et bornée par partie 4B; par le lot 6; par partie 4B à T.Massé; par la moitié sud-est dudit lot 4B.avec bâtisses.Enrg.#336721.The greater part of lot 9A-I8 of the XIth Range of Abercrombie bounded by Morin Street, on another line on the southeast bv P.9A belonging to A.Asselin, on the northeast partly by Rolland Street and partly by 9A-18-1, on the northeast by P.9A-18 belonging to B.P.Forcier and G.Pré-fontaine, on the northwest by 9A-18-1, on the northwest by P.9A-18 belonging to the said Forcier and Préfontaine, on the northwest by P.9A-18 belonging to J.-Robert Leblanc, on the northwest by lots 9A-5, 9A-8, 9A-5.All the rights of the vendor on a right of way on foot on a passage of 4' forming part 9A-P.4.9A-6.10A-19.The southeast part of lot 9A-19-P.15 being a common passage bounded by the remainder of the said lot belonging to Range Investments Limited, on the northeast by the northeast limit of the said lot, on the southeast by the common passage (9A-5), on the southwest by the southwestern boundary of the said lot.With buildings and furniture.Registration #333193.198.73 102.10 268.18 569.01 Xth Range of Morin.part 4B measuring 240' by 200' bounded by the main road, on the southeast and northeast by parts of 4B, on the northwest by lot 5.Part 4B of the 10th Range of Morin measuring 200' by half of the width of said lot 4B and bounded partly by 4B, lot 6, partly by 4B belonging to T.Massé, by the southeastern half of said lot 4B, with buildings.Registration #336721. 826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i' année, n\" A Taxes Taxes Taxes scol.scol.Noms Lots et cad.munie.cath.prot.Total Names Lots and cad.Munie.Cath.Prot.taxes school school taxes taxes Martineau.Gilles.PS-VII.Wexford.Du 7e rang Wexford, partie 5 ayant une superficie de 127.480 p.c.et bornée par P.5 a L.Woods Haslett; par la ligne limite entre les rangs 7 et 6; partie par P.5 et par une petite partie du chemin public; partie par le chemin public et partie par un emplacement triangulaire étant P.5.Enrg.#334183.Merle.Martha.5-47/VII.Wexford .Roberts, Mlle-Miss Anne.P4.P5/XI, Morin.De la partie des numéros 4 et 5 du lie rang Morin, comprenant tout le terrain, les fies, les pointes de terrain, l'eau, les ruisseaux, les lacs et rivières appartenant au vendeur dans lesdites parties des lots 4 et 5 entre le niveau des hautes eaux et la rive est de ladite rivière, entre les lignes de bornage des lots 3 et 4, et les lignes de bornage des lots 5 et 6, jusqu'à la borne ouest de la propriété du vendeur où elle touche à la propriété de Dame Edna Nelson, à distraire les parties vendues.Enregistrée #181783.Stalker.Ian C.Quinn, Mme-Mrs.Rhena.7B-1/2, Morin.2A-286/XI.Morin.2A-287/XI.Morin.2A-288/XI, Morin.2A-289/XI.Morin.2A-295/XI, Morin.2A-296/XI.Morin.2A-297/XI, Morin.2A-298/XI.Morin.2A-299/XI, Morin.2A-3-2/XI.Morin.2A-3-3/XI, Morin.2A-3-4/XI, Morin.2A-3-8/XI, Morin.3A-357/XI, Morin.3A-373/XI, Morin.3A-374/XI.Morin.3A-376/XI, Morin.3A-377/XI.Morin.3A-378/XI, Morin.2A-382/XI, Morin.3A-380/XI.Morin.4-7 /XI, Morin.3A-367/XI, Morin.3A-368/XI.Morin.3A-370/XI, Morin.4-6 /XI, Morin.4-6 /XI, Morin.S 387.36 S 188.60 8 575.96 7th Range of Wexford, part 5 containing 127,480 sq.ft.and bounded by P.5 belonging to L.Woods Haslett, by the boundary line between Ranges 7 and 6, partly by P.5 and by a small part of the public road, partly by the public road and partly by a triangular emplacement being P.5.Registration #334183.71.76 39.32 111.08 .508.68 657.79 1,166.47 Part of Nos.4 and 5 on the 11th Range of Morin, comprising all the land, islands, points of land, water streams, hikes and river owned by the vendor in said parts of lots 4 and 5 between the high water mark on the easterly bank of said river, between the boundary lines of lots 3 and 4, and the boundary lines of lots 5 and 6, to the westerly boundary of the property of the vendor where it adjoins the property of Dame Edna Nelson, less and to withdraw the parts sold.Enrg.# 181783.459.45 3,387.37 2,943.48 469.45 6,330.85 Municipalité de Val-Morin \u2014 Municipality of Val-Morin Taxes Taxes NomB Lots et cad.Rang munie.scol.Names Lots and cad.Range Munie.School taxes taxes Bellerose, Mme-Mrs.Lise Ménard.P.22.11.t 315.02 S 315.02 Borné à l'ouest par un lac.en profondeur, et des deux autres Bounded on the west by a lake, in depth and on the other côtés par d'autres parties du même lot 22, sous le numéro two sides by other parts of same lot 22 under registration d'enregistrement 383223.number 383223.Bourdage, Paul.24-166.10.248.17 S 225.92 474 09 Bryson, John.P.17-18.19A.11 .15.39 23.50 38.89 Borné au sud-est: Montée Ouellette, sud-ouest: Canadian Bounded on the southeast by Montée Ouellette, on the Pacific, nord-ouest: par le lot numéro 19B, nord-est: par le lot southwest by Canadian Pacific, on the northwest by lot QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 827 Taxes Taxes Noms Lots et cad.Rang munie.scol.Total Names Lots and cad.Range Munie.School taxes taxes 1A, rang 10, Canton Wexford, acquis par acte enregistré numéro 287595.number 19B and on the northeast by lot 1A, Range 10, Township of Wexford, purchased by a deed registered under number 287595.Constantineau, Maurice.P.22.Borné au nord: emplacement de Pierre Miller, ouest: en partie par l'emplacement de Messieurs Roland et en partie par l'emplacement de Jean-Paul Hébert, sud: emplacement de Messieurs Roland, est: par un passage de quinze pieds de largeur séparant le terrain présentement vendu de l'emplacement de Monsieur Bariteau.Acquis par acte enregistré sous le numéro 288493.10.8 88.87 8 71.15 $160.02 Bounded on the north by the emplacement of Pierre Miller, on the west partly by the emplacement of Messrs.Roland and partly by the emplacement of Jean-Paul Hébert, on the south by the emplacement of Messrs.Roland and on the east by a passage of fifteen feet in width separating the land presently sold from the emplacement of Mr.Bariteau.Purchased by deed registered under number 288493.Wan Young, Mme-Mrs.Chon.6-55.Corbin, Paul A.P.23 B.Borné à l'est: par un chemin le long du lot numéro 23B-12, nord: par le lot numéro 23B-11, ouest: par la Rivière du Nord, sud: par une autre partie du lot numéro 23B, propriété de Mme Mollie Carpman Finkelstein, acquis par acte enregistré sous le numéro 330722.Chenier, Jacques.8-3.Durand, Paul.P.23.Borné au nord-ouest: par l'Avenue Legault, nord-est: par la rue Vendette, séparant ce lot du lot de Monsieur Jean S.Goldhamer, sud-ouest: par la propriété de Alec Feldman, sud-est: par le résidu dudit lot 23, acquis par acte enregistré sous le numéro 300934.Gauthier, Mme-Mrs Rolland.19-23.Groulx, Armand.P.25.Borné en avant par la 22ième Avenue, en arrière par le lot numéro 26 dudit plan et livre de renvoi officiel, sur un côté par une autre partie du lot numéro 25, (Madame Ida Rick-haus), l'autre côté par une autre partie du lot numéro 25, (Monsieur Goloff, avec bâtisse).Gerlach, Paul.2-88, 2-89.Lamothe, Hector.P.4.Borné en front vers le nord-est: par la nouvelle route numéro 11, d'un côté vers le nord-ouest: par une autre partie dudit lot 4 appartenant à Monsieur Fernand Lessard ou représentants, des deux autres côtés: par d'autres parties dudit lot 4 restant la propriété de Monsieur Albert Locas, acquis par acte enregistré sous le numéro 256186.Ludwig, Arnold & Welches S.P.4.Borné au nord-est: par la ligne de division des lots 3 et 4, sud-sud-ouest: par la route numéro 11, nord-ouest: par une autre partie dudit lot numéro 4 appartenant à Monsieur Roland Paquette ou représentants, acquis par acte enregistré sous le numéro 361422.Les entreprises R.D.Inc.P.24, 24-101.Borné en front par le chemin public, à l'arrière par une autre partie du lot numéro 24, sur un côté par une autre partie du lot numéro 24 figurant sur un plan préparé par le vendeur étant le lot numéro 200-1, de l'autre côté par le lot numéro 200-3, et le lot numéro 200-2 et par une partie du lot originaire numéro 24, acquis par acte enregistré sous le numéro 359844.Marquis, Gerald.P.3.Borné vers l'ouest: par le chemin du 6ième rang, nord-est: par une partie du lot originaire numéro 3, sud-est: par une autre partie du lot originaire numéro 3, (Emile Cochand), sud-ouest: par une autre partie du lot originaire numéro 3.acquis par acte enregistré sous le numéro 349855.Morin, André.22-60.Murtiueau, Aùùse.P.10 B.6.14.35 14.35 .11.83.82 31.12 114.94 Bounded on the east by a road along lot number 23B-12, on the north by lot number 23B-11, on the west by Rivière du Nord, on the south by another part of lot number 23B, property of Mrs.Mollie Carpman Finkelstein.Purchased by deed registered under number 330722.6.8.68 8.68 .10 .63.54 63.54 Bounded on the northwest by Legault Avenue, on the northeast by Vendette Street, separating this lot from the lot of Mr.Jean S.Goldhamer, on the southwest by the property of Alec Feldman and on the southeast by the remainder of said lot 23.Purchased by deed registered under number 300934.6.12.22 17.45 29.67 .10.76.47 42.35 118.82 Bounded in front by 22nd Avenue, in the rear by lot number 26 of the said official plan and book of reference, on one side by another part of lot number 25 (Mrs.Ida Rickhaus), on the other side by another part of lot number 25 (Mr.Goloff, with building).6.28.42 28.42 .5.7.05 7.05 Bounded in front on the northeast by new Highway Number 11, on one side on the northwest by another part of said lot 4 belonging to Mr.Fernand Lessard or representatives, on the other two sides by other parts of said lot 4 remaining the property of Mr.Albert Locas.Purchased by a deed registered under number 256186.6.51.61 51.61 Bounded on the northeast by the separating line of lots 3 and 4, on the south-southwest by Highway Number 11, on the northwest by another part of said lot number 4 belonging to Mr.Roland Paquette or representatives.Purchased by a deed registered under number 361422.10 .260.98 248.82 509.80 Bounded in front by the public road, in the rear by another part of lot number 24, on one side by another part of lot number 24 shown on a plan executed by the vendor being lot number 200-1, on the other side by lot number 200-3 and lot number 200-2 and by a part of original lot number 24, purchased by a deed registered under number 359844.6.10.32 10.32 Bounded on the west by the road of the 6th Range, on the northeast by a part of original lot number 3, on the southeast by another part of original lot number 3, (Emile Cochand) and on the southwest by another part of original lot number 3.Purchased by a deed registered under number 349855.102.58 130.47 89.32 130.47 191.90 828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104* année, n° 4 Taxes Taxes Noms Lots et cad.Rang munie.scol.Total Names Lots and cad.Range Munie.School taxes taxes Borné en front au nord-est: par un chemin privé, d'un côté au nord-ouest: par un autre chemin privé perpendiculaire au 5ième rang, autre côté au sud-ouest et à l'arrière au sud-est par le résidu du lot numéro 10B, propriété de Mme Marie-Jeanne Tremblay, acquis par acte enregistré sous le numéro 376755.Bounded in front on the northeast by a private road, on one side on the northwest by another private road perpendicular to the 5th Range, on the other side on the southwest and in the rear on the southeast by the remainder of lot number 10B, property of Mrs.Marie-Jeanne Tremblay.Purchased by a deed registered under number 376755.Menegas, Angelo.P.3.Borné au sud-est: par une rue portant le numéro de lot 3-190, sud-ouest: par la route numéro 11.nord-ouest: par une autre partie dudit lot numéro 3, nord-est: par le lot numéro 3-172, acquis par acte enregistré sous le numéro 348003.Une autre partie du numéro P.3, borné au nord-ouest et au sud-ouest par une autre partie dudit lot numéro 3, au sud-est par une autre partie dudit lot, acquis par acte enregistré sous le numéro 348002.Miller, Raymond.P.22, 23.Borné en front, vers le sud-ouest par la rue Morin, en arrière, vers le nord-est par un ruisseau, d'un côté vers le nord-ouest par le terrain de Monsieur Emile Boisseau et de l'autre côté, vers le sud-est par une autre partie dudit lot numéro 22, acquis par acte enregistré sous le numéro 374426.Morniroli, François (Frank).P.1.Borné en front vers le sud par le chemin du 6ième rang, vers l'est par l'emplacement de Annie Lenahan ou représentants, en arrière vers le nord par le résidu du lot numéro 1 appartenant à Roméo Trudeau ou représentants, et vers l'ouest par une lisière de quarante pieds d'un terrain situé entre l'emplacement et la ligne de division entre les lots numéro 1 et 2, acquis par acte enregistré sous le numéro 246557.Paré, Mme-Mrs.Joan L.13B-P.5.Turner, Mme-Mrs.MaryBall.P.13 B.Borné vers le nord-est et sud-est: par la Rivière du Nord, nord-ouest: par la propriété de Robert Wood, sud-ouest: par Mme Elisabeth É.MacKenzie, acquis par acte enregistré sous le numéro 234757.6.S 158.07 S 158.07 Bounded on the southeast by a street numbered 3-190, on the southwest by Highway Number 11, on the northwest by another part of said lot number 3 and on the northeast by lot number 3-172 purchased by a deed registered under number 348003.Another part of number P.3 bounded on the northwest and southwest by another part of said lot number 3, on the southeast by another part of the said lot purchased by a deed registered under number 348002.10.S 113.71 113.71 Bounded in front on the southwest by Morin Street, in the rear on the northeast by a stream, on one side on the northwest by the land of Mr.Emile Boisseau and on the other side on the southeast by another part of said lot number 22, purchased by a deed registered under number 374426.6.136.12 136.12 Bounded in the front on the south by the road of the 6th Range, on the east by the emplacement of Annie Lenahan or representatives, in the rear on the north by the remainder of lot number 1 belonging to Roméo Trudeau or representatives and on the west by a tract of land of forty feet situated between the emplacement and the separating line between lots numbers 1 and 2, purchased by a deed registered under number 246557.10.230.95 230.95 .11.46.90 18.20 65.10 Bounded on the northeast and southeast by Rivière du Nord, on the northwest by the property of Robert Wood, on the southwest by Mrs.Elisabeth E.MacKenzie.Purchased bv a deed registered under number 234757.Thompson, Henri.P.24.Borné vers le sud-ouest: par un chemin privé, nord-ouest: par l'emplacement de l'acheteur acheté de Monsieur N.Lucas, nord-est: par l'emplacemnet de Monsieur Napoléon Beaulne, sud-est: par l'emplacement de Monsieur C.Dunnington, acquis par acte enregistré sous le numéro 280698.Borné vers le sud-ouest: par un chemin privé, nord-ouest: par la propriété de L.Valiquette, nord-est: par Monsieur Napoléon Beaulne, sud-est: par le vendeur Monsieur Norman Lucas, acquis par acte enregistré sous le numéro 268226.6.31.83 140.32 172.15 Bounded on the southwest by a private road, on the northwest by the emplacement of the purchaser bought from Mr-N.Lucas, on the northeast by the emplacement of Mr.Napoléon Beaulne and on the southeast by the emplacement of Mr.C.Dunnington, purchased by a deed registered under number 280698.Bounded on the southwest by a private road, on the northwest by the property of L.Valiquette, on the northeast by Mr.Napoléon Beaulne and on the southeast by the vendor, Mr.K-0/™?Lucas- Purchased by a deed registered under number 268226.Val-Royal Lake Resort.5.726.45 1,535.23 2,261 68 Lots, cad.\u2014 19-2.3, 4, 5, 6, 10, 12, 19-19, P.20, P.21, P.22.19-24.20-6, 20, 23, 24.35, 36, 37, 38.39 40 41 44 4', 4fi 47,58,59,64,75,82.83.86,87,88,89.90,91,92.93,94,21-14,16,23,24,25,26,27,28.53,58,59,60 61 62 63 64 23-93 ' 30 33.34,36,54,56,67,24-10,30,31,32,33,39,40.' ' ¦\"*\u2022«*\u2022*»\u2022 Reid, Jean-Guy.P.1.Borné vers le nord-est: par un terrain du même lot appartenant à Monsieur Armand Beauvais ou représentants, nord-ouest: par un autre terrain du même lot vendu à Monsieur Roger Lafieur, sud-est: par une autre partie dudit lot vendu à Monsieur Victor Constantineau, sud-ouest: par un chemin privé, acquis par acte enregistré sous le numéro 326862.6.7.20 8.69 15.89 Bounded on the northeast by a piece of land of the same lot belonging to Mr.Armand Beauvais or representatives, on the northwest by another piece of land of the same lot sold to Mr Roger Lafleur, on the southeast by another part of the said lot sold to Mr.Victor Constantineau and on the southwest by a private road.Purchased by a deed registered under number 326862.Ross, J.Delbert.P.24.1° Borné en front vers le nord par un chemin privé, appartenant au vendeur, étant une partie originaire du lot 24, sur .6.142.96 199.27 342.22 1.Bounded in front on the north by a private road belonging to the vendor, being an original part of lot 24.on one sido QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 829 Noms Na Lots et cad.Lots and cad.Rang Range Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total un côté vers l'est par une autre partie non subdivisée dudit lot, appartenant au vendeur, en arrière vers le sud par le Lac Charbonneau, et d'un autre côté vers l'ouest par ledit lot.2° Borné en front vers le nord-est par un chemin privé appartenant au vendeur et étant une partie du lot originaire numéro 24, en arrière vers le sud par le Lac Charbonneau et sur l'autre côté vers l'ouest par ledit lot.3° Borné en front vers le nord-est par un chemin privé, étant une partie du lot originaire numéro 24 et appartenant au vendeur, sur un côté vers l'ert par la description numéro 2, une partie dudit lot, en arrière vers le sud par le Lac Charbonneau, et sur l'autre côté vers l'ouest par une partie dudit lot, appartenant au vendeur, acquis par acte enregistré sous le numéro 295185.on the east by another non subdivided part of the said lot belonging to the vendor, in the rear on the south by Charbonneau Lake and on another side on the west by the said lot.2.Bounded in front on the northeast by a private road belonging to the vendor being a part of original lot number 24, in the rear on the south by Charbonneau Lake and on the other side on the west by the said lot.3.Bounded in front on the northeast by a private road being a part of original lot number 24 belonging to the vendor, on one side on the east by description number 2, a part of the said lot, in the rear on the south by Charbonneau Lake and on the other side on the west by a part of the said lot belonging to the vendor, purchased by a deed registered under number 295185.Shecter, Mme-Mrs.Irma.2-43,3-17.6.S 38.67 8 54.95 8 93.62 Sheehan, Jerome.2-292,2-293 .6.162.60 162.60 Veinish, Louis.10.34.89 60.90 85.79 Lots, cad \u2014 24-121, 122, 123, 124.126, 127.128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136.137, 139, 146.147, 148, 149, 156.161, 162, 167.Heselton, Douglas L.P.13B, P.19A.P.17 et P.18.Borné vers le sud-ouest et sud-est: par une partie du lot 13B-32, nord-ouest: par une autre partie du lot 13B, nord-est: par une autre partie du lot 13B-32 appartenant à Mme Jeannine Papineau Couture Leclerc, acquis par acte enregistré sous le numéro 328743.Borné vers le sud-ouest: par l'ancienne route numéro 11, nord-ouest et nord-est: par une autre partie non subdivisée du lot numéro 19A, sud-est: par une autre partie dudit lot numéro 19A, appartenant à Mme Monique Ouellette Lepage ou représentants.Borné au nord-est: par la rue conduisant à la Station, est: par le terrain de Monsieur Blair, sud-est: par le lac Raymond, sud-ouest: par le Lac Raymond, nord-ouest: par le chemin conduisant à Ste-Agathe, acquis par acte enregistré sous le numéro 280632.Dubuc, Mme-Mrs Lionel J.12B-8.Les lots ci-dessus font partie du cadastre officiel du Canton Morin.10.11 877.67 472.18 1,349.85 Bounded on the southwest and southeast by a part of lot 13B-32, on the northwest by another part of lot 13B, on the northeast by another part of lot 13B-32 belonging to Mrs.Jeannine Papineau Couture Leclerc, purchased by a deed registered under number 328743.Bounded on the southwest by former Highway Number 11.on the northwest and northeast by another non subdivided part of lot number 19A, on the southeast by another part of said lot number 19A belonging to Mrs.Monique Ouellette Lepage or representatives.Bounded on the northeast by a street leading to the Station, on the east by the land of Mr.Blair, on the southeast by Lac Raymond, on the southwest by Lac Raymond and on the northwest by the road leading to St.Agathe.Purchased by a deed registered under number 280632.10 .264.77 264.77 The lots hereabove are part of the official cadastre of the Township of Morin.Far Hills Inn.4A-1 à-to 19, 4A-22, 23, 5-B- 2,7,8.9,10.11,6-3,4,6.10 .3,649.74 4,535.69 8,085.43 Le lot ci-dessus fait partie du cadastre officiel du Canton The lot hereabove is part of the official cadastre of the Wexford.Township of Wexford.Municipalité du village de Val-David \u2014 Municipality of the village of Val-David Farband Labour Zionist Order.P.37.10.8 2.488.76 8 2,488.76 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro As described in the deed registered under number 386844.386844.Wainberg, W.P.40.Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 235245.Meyer.H.P.40.Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 169793.10.86.16 S 18.29 104.45 As described in the deed registered under number 235245.10.13.74 9.23 22.97 As described in the deed registered under number 159793.Kersys, Antanas.27-67.27-68.11.Lamarche, Pierre.27-187.11.Werzburger, Salomon.P.40.10.Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 258498.Les lots ci-dessus sont situés dans le Canton Morin, cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Agathe-deo-Monta.31.97 8.78 129.78 19.24 27.72 31.97 28.02 167.50 As described in the deed registered under number 258408.The abovementioned lots are situated in the Township of Morin, official cadastre of the Parish of St.Agatbe-des-Monts. 830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S9 janvier 197S, 10V année.n° h Paroisse de Sainte-Marguerite du Lac Masson \u2014 Parish of Sainte-Marguerite du Lac Masson Taxes Taxes Noms Lots et cad.Rang Canton munie.scol.Total Names Lots and cad.Range Township Munie.School taxes taxes Duhamel.Maurice.P.62.0.Wexford.S 02.03 * 62 03 Borné en front par le chemin public, au sud.au nord-est et Bounded in front by the public road, on the south, north-et à l'est: par le vendeur Maurice Duhamel.east and east by the vendor, Maurice Duhamel.Meleiro, José Auraro.P.20.7.Wexford.63.16 $ 39.06 92.22 Borné à l'est: par le lot 20-58, au sud-est: par parties non Bounded on the east by lot 20-58, on the southeast by non subdivisées du lot 20 rang 7, au nord-ouest: par une rue de subdivided parts of lot 20, Range 7, on the northwest by a 40 pieds de largeur étant une partie du lot 20, rang 7.street 40 feet wide being a part of lot 20, Range 7.Lavoie, Emile.P.25.7.Wexford.41.04 34.60 75.64 Borné en front: vers l'ouest par le chemin conduisant de Bounded in front on the west by the road leading from St.Ste-Marguerite à Ste-Lucie, d'un côté vers le sud par un Marguerite to St.Lucie, on one side on the south by an em-emplacement vendu par Charles Laçasse à Wilfrid Charbon- placement sold by Charles Laçasse to Wilfrid Charbonneau, neau, vers l'est et vers le nord par le résidu du lot 26 appar- on the east and north by the remainder of lot 25 belonging to tenant au vendeur.the vendor.Béliveau.Jean-Guy & Yvon.41-36.7.Côté, Jacques.43-3.7, Constantine, Rodric Eliescu.44-14.7 Deschambeault, Roger.P.41.7.Partant du coin ouest du lot 41-16 du rang 7, se dirigeant dans une direction sud-ouest sur la ligne de division entre les lots 41 rang 7, et 41 du rang 8, pour une distance de 78 pi., jusqu'au coin nord-est au point de départ de la parcelle de terrain faisant l'objet de la présente description technique; sud-ouest par sur la ligne de division entre les lots 41 rang 7, et 41 rang 8, pour une distance de 129 pi., vers le sud-est pour une distance de 7 pi., plus ou moins jusqu'au bord du Lac; vers le nord-est pour une distance de 128 pi., en suivant le bord du Lac; vers le nord-ouest pour une distance de 5 pi., jusqu'au coin nord-est du terrain faisant l'objet dé la présente description technique.Bornée au nord-est: par une partie non subdivisée du lot 41 du rang 7, au nord-ouest par une partie du lot 41 rang 8, ci-aprés décrite: Au sud-ouest: par une autre partie non subdivisée du lot 41 rang 7, et au sud-est par le Lac.Deschambeault, Roger.P.41.8.Partant du coin ouest du lot 41-16 rang 7, se dirigeant dans une direction sud-ouest sur la ligne de division entre les lots 41 rang 7 et 41 rang 8, pour une distance de 78 pi., jusqu'au coin sud-est au point de départ de la parcelle de terrain faisant l'objet de la présente description technique; vers la même direction sud-ouest sur la ligne de division entre les lots 41 rang 7 et 41 rang 8, pour une distance de 129 pi., se dirigeant dans une direction nord-ouest pour une distance de 120 pi., se dirigeant dans une direction nord-est pour une distance de 149 pi., se dirigeant dans une direction sud-est pour une distance de 110 pi., jusqu'au coin sud-est de la parcelle de terrain faisant l'objet de la présente description technique.Bornée au sud-est: par une partie du lot 41 du rang 7, ci-haut décrite, au nord-est: par une partie du lot 41 rang 8, au nord-ouest: par une rue projetée partie du lot 41 du rang 8, au sud-ouest: par une autre partie du lot 41 du rang 8.Wexford.06.90 39.85 106.75 Wexford.171.51 54 44 225.96 Wexford.142.61 40.89 183.50 Wexford.23.64 27.33 50.97 Starting at the west corner of lot 41-16 of Range 7, southwesterly on the separating line between lots 41, Range 7 and 41 of Range 8.78 feet to the northeast corner at the starting point of the tract of land, the technical description of which follows: On the southwest by the separating line between lots 41, Range 7 and 41, Range 8.129 feet, southeasterly 7 feet, more or less to the shore of the Lake, on the northeast 128 feet along the shore of the Lake, on the northwest 5 feet to the northeast corner of the land now described.Bounded on the northeast by a non subdivided part of lot 41 of Range 7, on the northwest by a part of lot 41, Range 8, hereinafter described: On the southwest by another non subdivided part of lot 41, Range 7, and on the southeast by the Lake.,.Wexford.143.CS 109.82 252.90 Starting at the west corner of lot 41-16.Range 7 in a southwesterly direction on the separating line between lots 41, Range 7 and 41.Range 8,78 feet to the southeast corner at the starting point of the tract of land, the technical description of which follows: In the same southwesterly direction on the separating line between lots 41.Range 7 and 41.Range 8.129 feet in a northwesterly direction 120 feet, in a northeasterly direction 149 feet, in a southeasterly direction 110 feet to the southeast corner of the tract of land, the technical description of which follows: Bounded on the southeast by a part of lot 41 of Range 7 hereinabove described, on the northeast by a part of lot 41, Range 8, on the northwest by a planned street, part of lot 41 of Range 8, on the southwest by another part of lot 41 of Range 8.Humnisky, Vladimir .P.26.9.Wexford.149.16 54.40 203.66 Borné en front: vers le sud-ouest par un chemin privé de Bounded in front on the southwest by a private road of 26 25 pi., de largeur, nord-est: par une autre partie du lot 26, feet in width, on the northeast by another part of lot 26.on one sur un côté vers le nord-ouest par une autre partie du lot 26, side on the northwest by another part of lot 26 belonging to appartenant à Michael Madden.Michael Madden.A QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol 101, No.L 831 Municipalité de Sainte-Lucie \u2014 Municipality of Sainte-Lucie Noma\tLota et cad.\tRang\tTaxes munie.\tTaxes scol.\tTotal Names\tLots and cad.\tRange\tMunie, taxes\tSchool taxes\t \t.17-298,312.\tIII.\t$ 30.00\tS 39.02\t8 69.02 \t.10-33, 17-5.\tIll.\t250.00\t103.98\t353.98 \t.16-232,233.\tIll.\t45.00\t42.10\t87.10 \t.16-138,174,175,176,177,.\tIll.\t229.00\t181.36\t410.36 \t178, 179.180, 330, 332, 334, 344, 346, 348, 360, 362, 366, 443, 444, 17-78, 80, 82, 84, 86, 112, 114 116, 340, 342, 344, 346.348 384, 438.\t\t\t\t \t.P.du lot 22.\tVI.\t45.00\t\t45.00 Terrain de forme irrégulière, d'une superficie d'environ A piece of land of an irregular configuration of about 14,000 14,000 pieds, et borné comme suit: par le Lac Sarrazin, par sq.feet, bounded as follows: by Sarrazin Lake, a stream, a un ruisseau, par un chemin privé et par Mme Berthe Coutu private road and by Mrs.Berthe Coutu Reid.Registration Reid.Enregistrement No 135,336.No.135,336.\t.17-454.\t.III.5.00\t11.00\t16.00 \t.29-79.\t.VI.5.00\t11.00\t16.00 Labelle, Laurier.\t\t.VI.5.00\t11 .00\t16.00 \t.29-298.\t.VI.5.00\t11.00\t16.00 \t.30-183.\t.VI.5.00\t11.00\t16.00 Labelle, Laurier.\t.30-247.\t.VI.5.00\t11.00\t16.00 \t.29-353.\t.VI.8.00\t\t8.00 Liberta, Gino.\t.17-136.\t.III.11.00\t8.40\t19.40 \t.18B-35.\t.III.375.00\t\t375.00 Signori, Jean-François.\t.16-123, 151, 152.\t.III.250.00\t68.15\t318.15 Venne, Roland.\t.17-144.442.\t.III.65.00\t5.77\t70.77 Tous les lots ci-dessus sont du cadastre officiel du Canton All the lots hereabove are of the official cadastre of the\t\t\t\t de Doncaster.\t\ttownship of Doncaster.\t\t Municipalité de Val-des-Lacs \u2014 Municipality of Val-des-Lacs\t\t\t\t \t\tTaxes\tTaxes\t Noms\tLots et cad.\tRang Canton munie.\tscol.\t \t\t\t\tTotal Names\tLots and cad.\tRange Township Munie.\tSchool\t \t\ttaxes\ttaxes\t \t.12.\t12____ Archambault.8 16.66\t\t8 16.56 Municipalité de Lac Carré \u2014 Municipality of Lac Carré Taxes Noms Lots et cad.Rang munie Names Lots and cad.Range Munie taxes Les Investissements J.M.Deslauriers.P.27B9.7.S 17.00 8 7.60 8 24.60 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 374449.As described in the deed registered under number 374449.Grenier, J.-René.P.27B2, P.27B15, P.27B6.7.17.00 7.60 24.60 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 374447.As described in the deed registered under number 374447.Grenier, J.-René.P.26-11.7 .753.25 675.50 1,428.75 Tel que désigné daus l'acte eniegistré sous le numéro 371779.As described in the deed registered under number 371779.Taxes scol.Total School taxes S32 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 janvier 1972.104' année, n\" 4 Nome Names Lots et cad.Lots and oad.Taxes Rang munie.Range Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total Bergevin, Robert.26-11-20.7.$ 37.20 Trudick, Mme-Mrs.Susan Kozell.P.28al.7.354.60 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 382172.As described in the deed registered under number 382172.S 27.65 * 64.85 110.60 465.20 Filiatreault, G.-Etienne.28F6.Mayer, Noella.P.27J7-2J- Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 370960.Les lots ci-dessus font partie du cadastre officiel du Canton de Wolfe.7.10.10 10.45 20.55 ____ 7.439.45 208.55 648.00 As described in the deed registered under number 370960.The abovementioned lots are part of the official cadastre of the Towijsl.ii.of Wolfe.Municipalité de Lac Supérieur \u2014 Municipalité of Lac Supérieur Bourdeau.Rolland.26-118.10.8 8.10 $ 12.05 8 20.16 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 316359.As described in the deed registered under number 316359.Brazeau, Yvan.P.32-66.8 .44.60 69.70 114.30 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 327884.As described in the deed registered under number 327884.Chenel, Mile-Miss Eugénie.P.32 .8 .8.10 12.05 20.16 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 311595.As described in the deed registered under number 311595.Cozzi.Mme-Mrs.Rita.P.25.10.139.65 214.05 353.60 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 296832.As described in the deed registered under number 295832.Flock, Joseph.P.25.10.21.35 31.20 62.65 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 295100.As described in the deed registered under number 296100.Fournier, Rosaire.P.32-56.8 .44.60 69.70 114.30 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 330386.As described in the deed registered under number 330386.Frechette, Claude.P.32-12.8.8.10 12.05 20.15 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 327889.As described in the deed registered under number 327889.Gauthier, Maurice.26-51.26-52.10.30.65 67.35 98.00 Tel désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 336908.As described in the deed registered under number 335908.Lafrenière.J.-B.26-56,26-57.10 .30.00 60.00 80.00 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 364564.As described in the deed registered under number 354554.Milette, Marguerite.P.26.8.15.46 31.35 40.80 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 286229.As described in the deed registered under number 286229.Grenier.Mme-Mrs.Cécile.16-226.16-227,16-228.8.21.35 40.25 61.60 16-229.16-230.16-231.Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 384963.As described in the deed registered under number 384963.Grant.Jean-G.12-210,12-211.8.11.45 26.20 37.65 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 352762.As described in the deed registered under number 352752.Kay Entreprise Ltd.P.22.8.15.45 58.55 74.00 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 274685.As described in the deed registered under number 274686.La Vallée du Nord.P.12.8.800.10 1,520.90 2,327.00 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 372443.As described in the deed registered under number 372443.Légaré, Chas.A.P.29A.7.8.10 36.76 44.85 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 121731.As described in the deed registered under number 121731.Malouin, Yvon.P.27.11.69.16 92.75 161.90 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 331176.As described in the deed registered under number 331175.Peterson, Courtney.Coudre.Marc.P.37.11.15.45 79.00 94.46 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 192480.As described in the deed registered under number 19248d. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10i, No.A 833 Taxes Taxes Noms Lots et ead.Rang munio.scol.Total Names Lots and cad.Range Munie.School taxes taxes Roy, Pinkney.15-352.8.$ 18.60 8 26.05 $ 44.55 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 289153.As described in the deed registered under number 289153.St-Arnaud, Jean-Paul.P.32-31.8.73.75 115.80 189.65 Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 327894.As described in the deed registered under number 327894.WUcox, Louis.15-537,15-538,15-539,16-540, 8 .26.80 50.06 76.85 15-541.16-651, 15-552, 16-553, 15-554, 15-555.Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 270846.As described in the deed registered under number 270846.Lépino, Maurice.P.27.11.110.30 173.60 283.80 Tel que désigné danB l'acte enregistré sous le numéro 328833.As described in the deed registered under number 328833.Les lots ci-dessus font partie du cadastre officiel du canton The lots hereabove are part of the official cadastre of the de Wolfe.Township of Wolfe.Municipalité de SaintrFaustin \u2014 Municipality of Saint-Faustin Bourque, Wilfrid.P.9.Terrain mesurant 150 pieds par 150 pieds, borné d'un côté par une montée et des trois autres côtés par le résidu du même lot, la ligne sud de cet emplacement étant distante d'environ 600 pieds de la ligne de division des rangs un et deux.Gosselin, Narcisse.P.21.Terrain mesurant 93 pieds en front au sud-est et est-sud-est, 200 pieds au sud-sud-ouest, 200 pieds au nord-est et 163 pieds au nord-ouest, borné au sud-est par le chemin public, au sud-sud-ouest par l'emplacement de M.J.Leduc et des autres côtés par parties du même lot.Gosselin, Narcisse.P-20a et-and P-21.Terrain portant le No P-20 et P-21 mesurant 100 pieds en front au sud-est, 200 pieds au sud-ouest, 189 pieds au nord-est et 100.4 pieds au nord-ouest, borné au sud-est par le chemin public, au sud-ouest par la partie du 21 ci-dessus décrite et des deux autres côtés par parties du même lot 21.Gosselin, Narcisse.P.20a.Terrain portant le No P-20a mesurant 10 pieds en front au nord-ouest le long du chemin public par la profondeur qu'il y a entre le chemin public et le Lac La Blanche, soit 30 pieds dans sa ligne nord-est et environ 30 pieds dans sa ligne sud-ouest et 10 pieds en bordure du lac au sud-est, borné au nord-ouest par le chemin public, au sud-ouest par partie dudit lot 20a à L.G.Hamelin, au nord-est par autre partie du lot 20a à Succession Dufour et au sud-est par le lac La Blanche.2.$ 40.66 8 91.30 $ 31.96 A piece of land measuring 150 feet by 150 feet, bounded on one side by a slope and on the other three sides by the remainder of the same lot.The south line of this emplacement about 600 feet from the separating line of Ranges one and two.4.30.26 34.86 66.11 A piece of land measuring 93 feet in front on the southeast and east-southeast, 200 feet on the south-southwest, 200 feet on the northeast and 163 feet on the northwest.Bounded on the southeast by the public road, on the south-southwest by the emplacement of Mr.J.Leduc and on the other sides by parts of the same lot.4.11.60 79.01 90.51 A piece of land numbered P.20a and P.21 measuring 100 feet in front on the southeast, 200 feet on the southwest, 189 feet on the northeast and 100.4 feet on the northwest, bounded on the southeast by the public road, on the southwest by part of 21 described above and on the other two sides by parts of same lot 21.4.6.45 17.30 22.75 A piece of land numbered P.20a measuring 10 feet in front on the northwest along the public road by the depth between the public road and La Blanche Lake.30 feet on its northeast line and about 30 feet on its southwest line, 10 feet by the Lake on the southeast, bounded on the northwest by the public road, on the southwest by part of said lot 20a belonging to L.G.Hamelin, on the northeast by another part of lot 20a belonging to the Dufour Estate and on the southeast by La Blanche Lake.Laplante, No81.P.39.Terrain mesurant 110 pieds en front à l'ouest-sud-est, 100 pieds en arrière à l'est, 75 pieds de profondeur dans sa ligne sud, et 110 pieds de profondeur dans sa ligne nord.Borné à l'ouest-sud-ouest par un chemin privé de 20 pieds de largeur, au sud par le terrain de Denise Trompette c.a.d., par une ligne Bituée à 423 pieds au nord de la ligne de division des rangs 5 et 4, h l'est par le lot 38 et au nord par le résidu dudit lot.5.12.70 3.92 16.62 A piece of land measuring 110 feet in front on the west-Boutheast, 100 feet in the rear on the east, 76 feet in th on its south line and 110 feet in depth on its north line.Bounded on the west-southweBt by a private road 20 feet in width, on the south by the land of Denise Trompetto, that is to say, by a line situated at 423 feet north of the separating Une of Ranges 6 and 4, on the east by lot 38 and on the north by the remainer of the said lot.Meszaros, Jim.P.17.Terrain mesurant 64.7 pieds en front, 65 pieds en arrière, 108.65 d'un côté et 127.1 pieds de l'autre côté, cet emplacement étant désigné sous le numéro 17-62 sur un plan non officiel de Leopold Moretti, a.u.6.50.10 .17.08 67.18 A piece of land measuring 64.7 feet in front, 66 feet in the rear, 108.65 on one side and 127.1 feet on the other side, this emplacement being described under number 17-62 on an unofficial plan of Leopold Moretti, i.s. 834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S9 janvier 197S, 101,' année, n° l Taies Taxes Noms Lots et cad.Rang munie.scol.Total Names Lots and cad.Range Munie.School taxes taxes Niger, Jean-Pierre.P.17.6.$ 77.20 $19.69 $96.89 Terrain mesurant 75 pieds en front, 30 pieds en arrière, A piece of land measuring 75 feet in front, 30 feet in the rear, 100 et 108.65 pieds sur les deux autres côtés, cet emplacement 100 and 108.65 feet on the other two sides, this emplacement étant désigné sous le numéro 17-61 sur un plan non officiel being described under number 17-61 on an unofficial plan of de Leopold Moretti, A.n.Leopold Moretti, l.b.Jules Couillard Després.10-1-1.7.15.77 41.17 66.94 Terrain mesurant 50' x 173.8' x 160' x 93', désigné sous le A piece of land measuring 60' x 173.8' x 160' x 39' described numéro 32 sur un plan non officiel de Jacques Poulin, a.g.under number 32 on an unofficial plan of Jacques Poulin, L.8.Jules Couillard Després.10-1-2.7.15.40 40.66 55.96 Terrain mesurant 50' x 43.5' x 160' x 40'.désigné sous le A piece of land measuring 50' x 43.5' x 160' x 40'.described numéro 31 sur un plan non officiel de Jacques Poulin, a.g.under number 31 on an unofficial plan of Jacques Poulin, L.s.Jules Couillard Després.10-1-3 .7.18.08 48.68 66.66 Terrain mesurant 50' x 143.5' x 130' x 40', désigné sous le A piece of land measuring 50' x 143.6' x 130' x 40', described numéro 30 sur un plan non officiel de Jacques Poulin, a.o.under number 30 on an unofficial plan of Jacques Poulin, l.s.Jules Couillard Després.10-1-4.7.15.15 40.66 55.31 Terrain mesurant 50' x 130' x 116.5' x 40', désigné sous le A piece of land measuring 50' x 130' x 116.5' x 40, described numéro 29 sur un plan non officiel de Jacques Poulin, a.g.under number 29 on an unofficial plan of Jacques Poulin, l.s.Jules Couillard Després.10-1-5.7.15.15 40.56 65.31 Terrain mesurant 50' x 116.5' x 115' x 40', désigné sous le A piece of land measuring 50' x 116.5' x 115' x 40', described numéro 28 sur un plan non officiel de Jacques Poulin, a.o.under number 28 on an unofficial plan of Jacques Poulin, l.s.Jules Couillard Després.10-1-6.7.15.15 40.56 55.31 Terrainmesurant 50' x 115' x 107.2' x 40', désigné sous le A piece of land measuring 50' x 115' x 107.2' x 40', described numéro 27 sur un plan non officiel de Jacques Poulin, a.o.under number 27 on an unofficial plan of Jacques Poulin, l.s.Jules Couillard Després.11-4-1.7 .20.23 50.58 70.81 Terrain mesurant 50' x 182.5' x 164' x 51.4', désigné sous le A piece of land measuring 50'x 182.5'x 164'x 51.4, described numéro 4 sur un plan non officiel de Jacques Poulin, a.g.under number 4 on an unofficial plan of Jacques Poulin, l.s.Jules Couillar 1 Després.11-4-2.7.19.95 50.13 70.08 Terrain mesurant 50' x 164' x 150' x 51.4'.désigné sous le A piece of land measuring 50' x 164' x 150' x 51.4', described numéro 5 sur un plan non officiel de Jacques Poulin, a.g.under number 5 on an anofficial plan of Jacques Poulin, l.8.Jules Couillard Després.P.11.7.17.55 45.96 63.51 Terrain mesurant 50' x 136.9' x 129.7\" x 50.8', désigné sous A piece of land measuring 50' x 136.9' x 129.7' x 50.8', le numéro 7 sur un plan non officiel de Jacques Poulin, a.g.described under number 7 on an unofficial plan of JacQues Poulin, l.s.Jules Couillard Després.P.12.7.77.20 226.07 303.27 Terrain mesurant 50' par 100', borné en front au nord par A piece of land measuring 50' x 100', bounded in front on une rue portant le No 12-5 et des autres côtés par des parties the north by a street numbered 12-5 and on the other sides du même lot 12, l'angle nord-est dudit emplacement étant by parts of same lot 12, the northeast angle of the said ein-situé à une distance de 197.1 pieds à l'ouest-nord-ouest des placement being situated 197.1 feet westnorthwest of streets rues 12-5 et 12-4.12-5 and 12-4.Les lots ci-dessus font partie du cadastre officiel du canton The abovementioned lots are part of the official cadastre Wolfe.of the Township of Wolfe.La commission scolaire de Saint-Jovite \u2014 The school commission of SaintrJovite Bédard, Jean-Paul.P.431.S 9.00 $ 30.14 $ 39.14 Un lopin de terre, de forme irrégulière, faisant partie du lot A tract of land of an irregular configuration being part of 431, mesurant 325' dans sa ligne sud environ 100' dans sa lot 431, measuring 326' on its south line and about 100' on ligne est, environ 100' dans sa ligne nord-est et environ 400' its east line, about 100' on its northeast line and about 400' dans sa ligne nord-ouest.Borné au sud par le lot 419 du même on its northwest line.Bounded on the south by lot 419 of the cadastre appartenant à Hilaire Therrien, à l'est par autre same cadastre belonging to Hiiaire Therrien on the east bv partie dudit lot 431 restant à Fernando Bédard ou représen- another part of said lot 431 remaining Fernando Bédard's or tants, au nord-est par le chemin public faisant le tour du lac representatives', on the northeast by the public road circlinc- Cinq et au nord-ouest par un autre chemin public conduisant lac Cinq and on the northwest by another public road lenHino au rang cinq., to Range five.leuuuig QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.k 835 Taxes Taxes Noms Lots et cad.Rang munie.scol.Total Names Lots and cad.Range Munie.School taxes taxes $ 6.60 $ 68.39 $ 74.99 Part of lot 207 measuring 210' by 130'.Bounded in front on the northwest by a road 25' in width being part of lot 207, on the other sides bounded by part of lot 207.As described in the deed registered under number 234395.Bori, Mme-Mrs.Julia, a/s-c/o P.207.La Curatelle Publique.Partie du lot 207, mesurant 210' par 130'.Borné en front vers le nord-ouest par un chemin de 26' de large faisant partie du lot 207, les autres côtés bornés par partie du lot 207.Tel que désigné dans l'acte enregistré sous le numéro 234395.Brunet, Mme-Mrs.Alice.208-626.3.45 Duval, Gérard.208-37, 208-705, 208-706, soit 37.95 le demi 706, sud-ouest, 208-814.Nanella, Joseph.208-547 .3.52 Pigeon, Normand.P.191.101.72 Partie du lot 191, mesurant 227' de large par 132' est, 142' Part of lot 191 measuring 227' in width by 132' east, 142' ouest, 227' par 100' de profondeur avec bâtisses.Tel que dési- west, 227' by 100' in depth with buildings As described in gné dans l'acte enregistré sousMe numéro 379104.the deed registered under number 379104.19.31 186.83 17.99 348.25 22.76 224.78 21.51 449.97 St-Pierre, Gilbert.P.190.P.191.Partie des lots 190 et 191, mesurant 330' de largeur par 242' de profondeur.Tel que désigné dans l'acte enregistrés sous le numéro 379104.Sargeant.James.208-694.Emond, Mile-Miss Marie-Lourdes.P.430.50.83 189.41 240.24 Part of lots 190 and 191 measuring 330' in width by 242' in depth.As described in the deed registered under number 379104.Partie du lot 430, mesurant 100' par 150' et 60' par 60'; borné par le chemin public, par la propriété de Dame Mar- Suerite Ladouceur ou représentants, par le lot 431, par partie u lot 430.Acquis par acte enregistré sous le numéro 288683.Kovesdi, Joseph.P.207.Partie du lot 207, mesurant 105' par 130'.Borné en front au nord-ouest par un chemin de 25' faisant partie du lot 207, en arrière au sud-est par le lot 207 ainsi que les autres côtés par lot 207.Acquis par acte enregistré sous le numéro 234017.Mlinkovics, Lajos.P.207.Partie du lot 207, mesurant 105' par 130'.Borné en front au nord-ouest par un chemin de 25' faisant partie du lot 207, en arrière au sud-est par le lot 207, ainsi que les autres côtés par lot 207.Acquis par acte enregistré sous le numéro 234019.1.60 11.76 13.26 .102.35 342.22 444.67 Part of lot 430 measuring 100' by 150' and 60' by 60', bounded by the public road, by the property of Mrs.Marguerite Ladouceur or representatives, by lot 431, by part of lot 430.Purchased by a deed registered under number 288683.6.45 37.67 44.12 Part of lot 207 measuring 105' by 130'.Bounded in front on the northwest by a road of 25' being part of lot 207, in the rear on the southeast by lot 207 and on the other sides by lot 207.Purchased by a deed registered under number 234017.9.90 24.14 34.04 Part of lot 207 measuring 105' by 130'.Bounded in front on the northwest by a road of 25' being part of lot 207, in the rear on the southeast by lot 207 and on the other sides by lot 207.Purchased by a deed registered under number 234019.Nadeau, Fernand.P.207.Deux parties du lot 207, mesurant respectivement 70' par 130' et 105' par 130'.Les deux parties sont bornées en front au nord-ouest par un chemin de 25' faisant partie du lot 207, en arrière au sud-est par lot 207, ainsi que les autres côtés par le lot 207.Acquis par acte enregistré sous le numéro 369204.11.00 38.46 49.46 Two parts of lot 207 measuring respectively 70' x 130' and 105' x 130'.Both parts are bounded in front on the northwest by a road of 25' being part of lot 207, in the rear on the southeast hy lot 207 and the other sides by lot 207 Purchased by a deed registered under number 369204.42.75 58.25 101.00 Veinish, Louis, a/s-c/o, Not.Erick 208-210, 208-712, 208-348, McLack.208-713,208-398.St-Laurent, Donat.P.435.20.62 142.01 162.63 Partie du lot 435, mesurant 100' par 80'.Borné au nord par Part of lot 435 measuring 100' by 80'.Bounded on the north le chemin public du Lac Renaud et des trois autres côtés, par by the public road of Lac Renaud and on the other three le résidu du terrain de Mlle Marie-Anne Forget ou représen- sides by the remainder of the land of Miss Marie-Anne Forget tenta- Acquis par acte enregistré sous le numéro 375913.or representatives.Purchased by a deed registered under number 375913.Veinish, Louis, a/s-c/o Me Eric Mc Lack, P.207.Partie du lot 207 selon les adjudications numéros 232 et 280.6.60 7.67 13.17 Part of lot 207 according to adjudication numbers 232 and 280.Sabourin, Paul.P.442.Partie du lot 432, mesurant 200' en front dans sa ligne nord-est 200' en arrière dans sa ligne sud-ouest 76' de profondeur dans sa ligne nord-ouest, 90' de profondeur dans sa ligne sud-est, borné au nord-est par la rivière de la Diable au nord-oueet par la partie du terrain vendu à Pierrette Gervais-Giraldeau par acte #304383 et partie par le terrain de Jules .23.61 62.81 86.42 Part of lot 442 measuring 200' in front on its northeast line, 200' in the rear on its southwest line, 75' in depth on its northwest line, 90' in depth on its southeast line, bounded on the northeast by Rivière de la Diable, on the northwest by part of the land sold to Pierrette Gervais-Giraldeau by deed #304383 and partly by the land of Jules Labonté or 836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Noms Names Lots et cad.Lots and cad.Rang Range Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total Labonté ou représentants.Au sud-ouest par un chemin privé de 15' de largeur.Au sud-est par le résidu du terrain de Jules Labonté ou représentants.Labonté, Orner.P.444.Un lopin de terre faisant partie du lot 444, mesurant, ce lopin de terre, 100' de largeur de l'est à l'ouest sur 100' de profondeur du sud au nord et borné en front au sud par un chemin public étant le chemin public continuant en ligne droite le chemin public se trouvant sur le lot 448, c'est-à-dire le chemin public le plus au nord sur ledit lot 444, à l'ouest par un autre chemin public, au nord et à l'est par le résidu du terrain de Jules Labonté ou représentants, la ligne est du terrain étant à 300' à l'ouest de la ligne divisant les lots 444 et 448.Acquis par acte enregistré sous le numéro 270545.Laberge, Donald.P.537.Un morceau de terrain formant partie du lot numéro cinq cent trente-sept (ptie 537), ladite pièce de terrain mesurant trois cent soixante-dix-sept pieds (377') de façade sur la ligne ouest, quatre cents pieds et trois dixièmes (400.3') en arrière sur sa ligne est, sur sept cent soixante-treize pieds et cinq dixièmes (773-5') de profondeur sur sa ligne sud et sept cent quatre-vingt-cinq pieds et cinq dixièmes (785.5') de profondeur sur sa ligne nord, et bornée en avant vers l'ouest par la ligne est de l'expropriation par le Ministère de la Voirie aux fins de la nouvelle route St-Jovite \u2014 Lac Ouimet, et sur les trois autres côtés par le résidu dudit lot cinq cent trente-sept appartenant à Edouard Emond, sauf et à distraire pour le premier cent pieds (100') sur la partie ouest de la ligne sud qui s'y trouve, le terrain présentement décrit est borné par l'emplacement de Charles Etienne Clermont.representatives.On the southwest by a private road 15' in width.On the southeast by the remainder of the land of Jules Labonté or representatives.S 31.08 $ 160.73 $ 191.81 A tract of land being part of lot 444, this tract of land measuring 100' in width from east to west by 100' in depth from south to north and bounded in front on the south by a public road being the public road continuing in a straight line along the public road on lot 448, that is to say the public road furthest north on said lot 444, west by another public road, north and east by the remainder of the land of Julea Labonté or representatives, the east line of the land being 300' west of the separating line of lots 444 and 448.Purchased by a deed registered under number 270545.226.92 226.92 A piece of land forming part of the lot number five hundred and thirty-seven (P.537), measuring, said piece of land, three hundred and seventy-seven feet (377') in frontage on the west line, four hundred feet and three tenths of a foot (400.3') in rear in its east line, by seven hundred and seventy-three feet and five tenths of a foot (773.5') in depth in its south line and seven hundred and eighty-five feet and five tenths of a foot (785.5') in depth in its north line, and bounded in front to the west by the east line of the expropriation by the Department of Roads for the new road St-Jovite \u2014 Lake Ouimet, and to the three other sides by the residue of said lot five hundred and thirty-seven belonging to Edouard Emond, save and except for the first one hundred feet (100') on the west part of the south line there where the land presently described is bounded by the emplacement of Charles Etienne Clermont.St-Laurent, Donat.P.407.Partie du lot 407, mesurant 110' en front dans sa ligne est environ 140' en arrière dans sa ligne ouest, 120' de profondeur dans sa ligne nord 109.3' de profondeur dans sa ligne sud.Borné à l'est, par l'ancienne et la nouvelle Route 11, au nord par un passage de 20' de largeur faisant partie du terrain vendu à M.Louis-J.Gadoury.A l'ouest, par le terrain de Monsieur Gadoury, au sud par le terrain de Mme Yvonne Dupras Dubois.Sujet à une servitude de non-construction mentionnée à l'acte enregistré sous le numéro 299992.Les lots ci-dessus font partie du cadastre officiel du Canton de Salaberry.150.90 20.25 171.15 Part of lot 407 measuring 110' in front on its east line and about 140' in the rear on its west line, 120' in depth on its north line, 109.3' in depth on its south line.Bounded on the east by the former and new Highway 11, on the north by a passage of 20' in width being part of the land sold to Mr.Louis-J.Gadoury.On the west by the land of Mr.Gadoury, on the south by the land of Mrs.Yvonne Dupras Dubois.Subject to a non construction servitude mentioned in the deed registered under number 299992.The abovementioned lots are part of the official cadastre of the Township of De Salaberry.Municipalité de Mont Tremblant \u2014 Municipality of Mont Tremblant Taxes Taxes Noms Lots et cad.Rang Canton munie.bcoI.Names Lots and cad.Range Township Munie.School taxes taxes Jean Ségumel Inc.P.33.2.Grandisson- S 3,012.48 $ 2,322.60 $ 5,335.08 Terrain mesurant 680 pi.x 295 pi.x 295 pi.x 26.4 pi.: A piece of land measuring 680' x 29.V t 9Qiv v oaI' aL.» Superficie 94.870 pi.ca.Avec bâtisses.94,870 sq.ft.With buildings ' Barnes, Romain.P.33.2.Grandisson____ 21.00 30.05 61 05 Terrain mesurant 65 pi.de profondeur sur 45 pi.de largeur A piece of land measuring 65 feet in depth bv 45 feet in de 1 est a 1 ouest, sans bâtisse.width from east to weBt, without buildings. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.m.No.L 837 Donné à St-Jérôme, au bureau de la corporation du comté de Terrebonne, ce 7e jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44037-3-2-o André Tassé.Municipalité du comté de Yamaska Avis public est par les présentes donné par le soussigné Robert Tessier, secrétaire-trésorier du conseil municipal du comté de Yamaska, que' les immeubles ci-après décrits seront vendus à l'enchère publique dans la salle des sessions dudit conseil au Palais de justice à St-François-du-Lac, JEUDI le NEUVIÈME jour de MARS 1972 à DIX heures de l'avant-midi pour défaut de paiement des taxes municipales et scolaires dues aux corporations ci-après mentionnées à moins que lesdites taxes et frais encourus ne soient payés avant la vente.Municipalité de la paroisse de St-Pie de Guire Comme appartenant à André Férir.\u2014 Une portion de terre en la paroisse de St-Pie de Guire, faisant front à la route du 10e rang, contenance de deux arpents de largeur sur trois de profondeur, le tout plus ou moins, tenant d'un bout au sud-ouest à ladite route, au nord-ouest au lot 441, étant parties des lots 82 et 83 du cadastre de ladite paroisse.Taxes municipales: $4.30; scolaires: 825.48.Total : $29.78.Municipalité de la paroisse de St-François du Lac Comme appartenant à Exéline Grenier et Zotique Grenier.\u2014 Les lots 446 et 450 du cadastre de la paroisse de St-François-du-Lac.Taxes dues municipales: $49.52; scolaires: $269.15.Total: $318.67.Comme appartenant à Joseph Méril Drolet.\u2014 Les lots 807 et 808 du cadastre de la paroisse de St-François-du-Lac.Taxes dues municipales: 80.32; scolaires: $3.44.Total.$3.76.Municipalité de la paroisse de St-Joachim de Courval Comme appartenant à Graziella Timmins.\u2014 Une portion de terre étant partie du No 787 du cadastre de la paroisse de St-Thomas de Pierreville, de la contenance de sept arpents de largeur par quinze arpents de profondeur étant la partie nord-ouest du No 787; à distraire la partie vendue à Southern Canada Power.Taxes dues municipales: 846.12; scolaires: 8240.35.Total: $286.47.Municipalité de la paroisse de St-David de Guire Comme appartenant à Joseph Verville.\u2014 Une portion de terre étant partie du No 342 du cadastre de la paroisse de St-David, de la contenance de trois arpents de largeur au bout sud-ouest et de un arpent et demi de largeur au bout nord-est sur une profondeur de douze arpents, borné au nord-est au chemin du 2e rang, au sud-ouest à Jos.Viens, d'un côté à la route divisant St-Guillaume et St-David, l'autre côté à Jos.Joyal.Taxes dues municipales: $71.08; scolaires: $95.04.Total: $166.12.Given at St.Jérôme, at the County of Terrebonne Corporation Office, this seventh day of January, 1972.André Tassé, 44037-3-2 Secretary-Treasurer.Municipality of the County of Yamaska Public notice is hereby given by the undersigned, Robert Tessier, Secretary-Treasurer of the Municipal Council of the County of Yamaska, that the immoveables hereinafter described will be sold by public auction in the Council Hall, in the Court House, at St.François-du-Lac, on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon in default of payment of municipal and school taxes due the corporations hereinafter mentioned unless the said taxes and costs incurred are paid before the sale.Municipality of the Parish of St.Pie de Guire Property of André Férir.\u2014 A tract of land in the Parish of St.Pie de Guire fronting the highway of Range 10, measuring two arpents in width by three in depth, the whole more or less, bounded at one end on the southwest by the said highway, on the northwest by lot 441, being part of lots 82 and 83 of the cadastre of the said Parish.Municipal taxes: $4.30; school taxes: $25.48.Total: $29.78.Municipality of the Parish of St.François du Lac Property of Exéline Grenier and Zotique Grenier.\u2014 Lots 446 and 450 of the cadastre of the Parish of St.François-du-Lac.Municipal taxes due: $49.52; school taxes : $269.15.Total : $318.67.Property of Joseph Méril Drolet.\u2014 Lots 807 and 808 or the cadastre of the Parish of St.François-du-Lac.Municipal taxes due: $0.32; school taxes: $3.44.Total: $3.76.Municipality of the Parish of St.Joachim de Courval Property of Graziella Timmins.\u2014 A tract of land being part of No.787 of the cadastre of the Parish of St.Thomas de Pierreville, measuring seven arpents in width by fifteen arpents in depth, being the northwest part of No.787; less and to withdraw the part sold to Southern Canada Power.Municipal taxes due: $46.12; school taxes; $240.35.Total: $286.47.Municipality of the Parish of St.David de Guire Property of Joseph Verville.\u2014 A tract oi land being part of No.342 of the cadastre of the Parish of St.David, measuring three arpents in width at the southwest end and one and one-half arpents in width at the northeast end by a depth of twelve arpents, bounded on the northeast by the road of the 2nd Range, on the southwest by Jos.Viens, on one side by the route separating St.Guillaume and St.David, on the other side by Jos.Joyal.Municipal taxes due: $71.08; school taxes: $95.04.Total: $166.12. 838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, lui' année, n'A Municipalité de la paroisse de St-Antoine de la Baie du Febvre Comme appartenant à Jean-Marie Lafond.\u2014 Un terrain vague situé en la première concession de ladite Paroisse de La Baie, en bordure de la route de l'église côté sud-ouest de cette dernière, mesurant cent pieds de largeur sur cent trente-six pieds de profondeur.Lequel emplacement est désigné au cadastre officiel de la paroisse de St-Antoine de La Baie, comme faisant partie du lot de terre No.524.Taxes dues municipales: 842.51 ; scolaires: $24.78.Total: $67.29.Donné à St-François-du-Lac, le 7 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44034-3-2-o Robert Tessier.Municipality of the Parish of St.Antoine de La Baie du Febvre Property of Jean-Marie Lafond.\u2014 A tract of vacant land situated in the first concession of the said Parish of La Baie, bordering the Route de l'Église on the southwest side of the latter, measuring one hundred feet in width by one hundred and thirty-six feet in depth.The said emplacement is described in the official cadastre of the Parish of St.Antoine de La Baie as being part of lot of land number 524.Municipal taxes due: $42.51; school taxes: $24.78.Total: $67.29.Given at St.François-du-Lac, January 7, 1972.Robert Tessier, 44034-3-2 Secretary-Treasurer.Municipality du comté de L'Islct Je, soussigné, Charles Fortin, secrétaire-trésorier de la Corporation Municipale du Comté de L'Islet, donne avis au public que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l'enchère publique le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures du matin, au Centre Paroissial de St-Jean Port-Joli, à St-Jean Port-Joli, Québec, faute de paiement de taxes municipales et scolaires auxquelles ces immeubles sont assujettis et des frais encourus.Municipality of the County of L'Islet I, the undersigned, Charles Fortin, Secretary-Treasurer of the municipal corporation of the County of L'Islet, give public notice the immoveables hereafter designated will be sold by public auction on the NINTH day of the MARCH, 1972, at TEN o'clock in the morning, at the St.Jean Port-Joli Parochial Center, in St.Jean Port-Joli, Québec, in default of payment of municipal and school taxes to which these immoveables are subject and the costs incurred.Corporation municipale de St-Omer \u2014 Corporation Municipale of St-Omer Taxes Taxes Propriétaire Désignation Munie.scolaires Frais \u2022 Total Proprietor Designation Munie.School Costs taxes taxes Médéric Avoine, St-Omer, Que.Lot no 31.rang-range 6, S 39.10 î 164.17 $ 203.27 canton-township Dionne.100 acres-acres Joseph Anctil, St-Omer, Que.Lot no 32, rang-range 6, 65.85 130.66 186.60 canton-township Dionne, 100 acres-acres.Guy Anctil, St-Omer, Que.Lot no 35, rang-range 1, 147.73 107.84 256.67 canton-township Dionne.98 acres-acres.Paul-Emile Daigle, St-Omer, Que.Lot no 35, rang-range 8, 68.35 104.31 172.66 canton-township Lafontaine, 100 acres-acres.Claude Fortin, St-Omer, Que.Lot no 60, rang-range 2, 80.85 50.69 131.44 canton-township Dionne, 100 acres-acres.Paul Alphonse Godbout, St-Omer, Que.Lot no 63.rang-range 2, 60.35 91.27 141.62 canton-township Dionne, 100 acres-acres.Rosaire Lapointe, St-Omer, Que.Lot no 62, rang-range 2, 80.85 69.09 139.94 canton-township Dionne.100 acres-acres.Cyprien Pelletier, St-Omer, Que.Lots nos.31 et 32, rang- 132.12 132.12 range 8, canton-township Lafontaine, 200 acres-acres.André Gagnon, St-Omer, Que.Lot no 39, rang-range 1, 77.91 77.91 canton-township Dionne, 100 acres-acres. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.A 839 Corporation municipale de St-Adalbert \u2014 Municipal Corporation of St-Adalbert Taxes Taxes Propriétaire Désignation Munie.scolaires Frais Total Proprietor Designation Munie.School Costs taxes taxes Mme-Mrs.Joseph Leclerc, St-Omer, Que- 8 64.65 $ 218.24 * 282.79 Lots nos 38 et 39.patentés, rang 5, canton Casgrain, 200 Lots Nos.38 and 39, patentes, range 5, Casgrain Township, acres; lots nos 40 et 41, patentés, rang 6, canton Casgrain 194 200 acres; lots Nos 40 and 41, patented, range 6, Casgrain acres; partie sud du lot no 41, rang 5, canton Casgrain pa- Township, 194 acres; south part of lot No.41, range 5, Cas-tenté, 35 acres.grain Township patented, 35 acres.Corporation municipale de St-Roch des Aulnaies \u2014 Municipal Corporation of St-Roch des Aulnaies Paul Caron, St-Roch des Aulnaies et St-Pam- S 21.06 S 102.07 $ 7.19 8 130.32 phile.Propriété située en 2e rang, portant le no ptie311, ayant une Property situated in the 2nd range, bearing No.Pt.311, superficie de 61 arpents, moins 1.2.91 arpents qui a été ex- having an area of 61 arpents, to withdraw 1.291 arpentexpro- proprié par la voirie.priated by the Department of Roads.Corporation municipale de Ste-Louise \u2014 Municipal Corporation of Ste-Louise Henri Doiron, Ste-Louise, Que.S 46.73 $ 101.26 $ 147.99 Ernest A.Levesque, Ste-Louise, Que.10.40 11.56 21.96 Gustave St-Pierre, Ste-Louise.Que.88.60 76.19 164.79 Partie du lot no 384, rang 2 lots nos 466 et 467, rang 2 partie Part of lot No.384, range 2, lots Nos.466 and 467, range 2, du lot no 318, partie du lot no 319 en partie du lot no 320, Part of lot No.318, part of lot No.319 and part of lot No.du rang 4.320, in range 4.Corporation municipale de St-Damase \u2014 Municipal Corporation of St-Damase André Dubé, St-Damase, Que.$ 21.90 $ 70.62 S 92.52 Maison 18 x 31 avec rallonge, et terrain 100 x 100 sur partie Hôuse 18 x 31 with extension, and lot of land 100 x 100 on dulotno 12,cantonFournier,rangA.partoflotNo.12, Fournier Township, range A.Corporation municipale de St-Marcel \u2014 Municipal Corporation of St.Marcel Jean-Guy Pelletier, St-Marcel.8 95.63 $ 0.82 8 96.46 Lot no 43, rang 4, canton Arago, superficie 100; lot no 41, Lot No.43, range 4, township of Arago.area 100; lot No.rang 6, canton Arago, superficie 50; lot no 32A rang 2, super- 41, range 6, Township of Arago, area 50;lot No.32A, range 2, ficie 40, canton Arago et lot no 33A, range 2 canton Arago, area 40, township of Arago and lot No.33A, range 2, Arago superficie 40.Township, area 40.Corporation municipale de St-Eugène \u2014 Municipal Corporation of St.Eugène Succession-Estate Théophile Bernier, St-Eu- Partie-Part du-of lot no 8 13.68 $ 9.14 S 0.67 8 23.39 gène, Que.162, rang-range 1.Roland Gagné, Cap St-Ignace.Lot no 462, rang-range 1 1.04 3.98 0.87 6.89 Lot no 2.Roland Pelletier, St-Cyrille.Partie-Part du-of lot no 140.36 85.51 9.16 236.01 388 du rang-in range 2.Andréa Gagnon, 21 rue Commerciale, St-Da- Partie du-of lot no 400.2.92 9.14 0.15 12.21 vid, cté Levis.rang-range 2.Corporation municipale de Notre-Dame de Bonsecours \u2014 Municipal Corporation of Notre-Dame de Bonsecours Ovila Marois, rang 2, L'Islet.Partie-Part du-of lot no $ 18.30 S 126.61 8 4.47 $ 149.38 606.Lueion Gagné, rang 2, L'Islet.Lots nos 460 et-and 462 38 66 182 66 9.46 228.67 840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10 k' année, n° L Propriétaire Proprietor Désignation Designation Taxea Munie.Munie, taxes Taxes scolaires School taxes Frais Costs Total Richard Journeault, rang 2, L'Islet.Partie-Part du-of lot no 641.lots nos 543, 644, 646 et-and 647.55.88 S 116.99 S 3.80 S 176.67 Corporation municipale de St-Jean Port-Joli \u2014 Municipal Corporation of St-Jean Port-Joli Armand Duval (Sylvio), St-Jean Port-Joli, Partie-Part du-of lot no $ 63.86 S 377.42 $ 5.14 * 436.42 60.Corporation municipale de St-Cyrille \u2014 Municipal Corporation of St-Cyrille Armand Carlos (Jos.), St-Cyrille, Que.Partie-Part du-of lot no 136, rang-range 2 Seigneurie de Lessard.24.80 $ 147.84 S 12.02 S 184.66 Ville de L'Islet \u2014 Town of L'Islet WUbrod Kirouac, ville de L'Islet, Que.$ 359.92 S 26.79 S 386.71 Partie du lot 584, un terrain seul et un terrain avec une Part of lot 584, a lot of land and a lot of land with a plan usine sur icelui.thereon.Corporation municipale de Ste-Perpétue \u2014 Municipal Corporation of Ste-Perpétue Edmond Beaulieu.Lot no 14A-1, rang-range S 10.28 t 176.42 A, canton-township Lafontaine.Edmond Beaulieu.Lot no 14A-17, rang- 286.44 403.10 range A, canton-township Lafontaine.Roland Joncas.Lot no 14A-21, rang- 155.68 32.39 range A.canton-township Lafontaine.Roland Beaulieu.Lots no 12-A-l-B-l et-and 344.63 401.61 13E, rang-range A, canton-township Lafontaine.Paul-Emile Ouellet.Lot 31, rang-range 7, La- 28.77 134.23 fontaine.Roméo Thibault.Lot 13.rang-range 1, can- 27.20 118.64 ton-township Garneau.t «86.70 689.64 188.07 746.14 163.00 145.84 Donné à St-Jean Port-Joli, ce 7e jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44031-3-2-o Charles Poulin.Given at St.Jean Port-Joli, this 7th day of January 1972.Charles Fortin, 44031-3-2 Secretary-Treasurer.Municipalité du comté des Deux-Montagnes Municipality of the County of Two Mountains Avis public est, par les présentes donné par le soussigné, Gustave Thériault, secrétaire-trésorier de la Corporation du comté des Deux-Montagnes, que JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972 à DIX heures de l'avant-midi en la Salle Municipale du Comté des Deux-Montagnes à Ste-Scholastique, les immeubles suivant seront vendus à l'enchère publique Public notice is hereby given by the undersigned Gustave Thériault.Secretary-Treasurer of the Corporation of County of Two Mountains, that THURSDAY, the NINTH day of MARCH.1972, at TEN o'clock in the forenoon, in the Hall of the County at Sainte Scholastique the following immoveable properties will, be sold at the public auction for municipal QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10Â, No.I 841 pour défaut de paiement de taxes municipales et and school taxes due on eiich of the same lots unless scolaires dues sur chacun de ces immeubles, à moins those taxes together with the costs incurred up be paid que ces taxes ne soient acquittées, avec les frais encou- before the sale to wit: rus, avant la vente, savoir: Municipalité partie nord paroisse de L'Annonciation (Oka) \u2014 Municipality north part of the parish of L'Annonciation (Oka) Montant Nom du propriétaire Numéro de lots dû Name of owner Number of lots Amount due Andronik, Peter.Lapierre, Jacques.¦.Beaulieu, Mme Renée.Bolduc, Claude.Rondeau, Gaston.Holmes, Grégoire.'.Villas Deux-Montagnes ltée.Paradis, Gilles.Désignation 13-P.74: Mesurant 5 pieds de largeur par 180 pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, borné au nord-ouest par le chemin qui conduit de la route publique à la Pointe aux Anglais, au 6ud-est en arriére, par une partie du No 13, d'un côtéau nord-est parlelot 13-74 et au sud-ouest par le No 13-76 ci-dessus.17-226,227,228,294.S 49.24 212-50.4.42 305-304.106.81 176-6-1.6.23 212-8.34.11 212-29.4.43 211-41.4.40 13-75 & 13-P.74.26.06 Designation: measuring 5 feet of width by 180 feet of depth, English measure and more or less, bounded to the northwest by the road conducting from the public road to the Pointeaux-Anglais, to the southeast in rear by a part of No.13, from one side to the northeast by lot 13-74 and to the southwest by No.13-75 hereinabove.Commission scolaire de St-Canut \u2014 School Commission of St.Canut Chartier, Robert.Lemieux, Yvon.Désignation: Ptie 95 cadastre de la Paroisse de St-Canut mesurant 200 pieds en ligne droite entre les coins nord et ouest, le long de la route publique et à l'arrière ou dans sa ligne sud-est, par une profondeur de 104.3 pieds dans ses lignes nord-est et sud-ouest; borné au nord-ouest par route No 41, en arrière et des autres côtés par a'autres parties du No 95.La ligne sud-ouest est distante de 106 pieds mesurés dans une direction nord-est de la ligne de division entre les lots 94 et 95; mesure anglaise.Désignation: P.96 cadastre de la Paroisse de St-Canut, mesurant 200 pieds de largeur par 200 pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, borné devant par l'emplacement ci-dessus décrit, d'un côté par Théophile Rochon ou représentants, de l'autre côté par Guy Me Kenzie ou représentants et en arrière par Eugène Proulx, ou représentants.Roe Hugh Hay 4 Grace Muriel Angus Archambault, Marcel.P.92-86.8 149.84 P.95.239.12 Designation: P.95 cadaster of the Parish of St.Canut, measuring 200 feet in right line between the northern and western corners, along the public road and at the rear or in its southeast line, by a depth of 104.3 feet in its northeast and southwest lines; bounded to the northwest by route No.41, in rear and from the other sides by other parts of lot 95.The southwest line is distance of 106 feet measured in an northeast direction from the division line between lots 94 ans 95, English measure.Designation: P.95 cadaster of the Parish of St.Canut, measuring 200 feet of width by 200 feet of depth, English measure and more or less, bounded in front by the emplacement hereinabove described, from one side by Théophile Rochon or representatives, from the other side by Guy Mc Kenzie or representatives and in rear by Eugène Proulx or representatives.Pt.94, 63, 74, 75, 76, 300.166.36 247-39, 40, 41.42, 43.246-79, 80, 81.102.68 Municipalité de la paroisse de St-Colomban \u2014 Municipality of the parish of St.Colomban Roger Martin Inc.Désignation: Un emplacement composé de: a) Une partie du lot No 75 aux cadastre de la Paroisse de St-Colomban, bornée en front à l'ouest et au nord par la ligne de division des Paroisses de St-Colomban et St-Jéruzalem et par le chemin public, en arrière au sud-est par une partie du No 76, d'un côté à l'ouest sud-ouest par la partie du lot No 76 ci-après décrite et de l'autre côté à l'est nord-est par le No 74; b) Une partie du lot No 76 au même cadastre, borné en front à l'ouest par la ligne de division deB Paroisses de St-Colomban et St-Jéruzalem, en arrière au sud sud-est par une partie ci-après décrite et par partie du No 78, et de l'autre côté à 1 est nord-est par le No 75 ci-dessus décrit; c) Une partie du lot No 79 au cadastre de la Paroisse de St-Colomban, bornée a 1 ouest par la ligne de division des Paroisses de St-Colomban et St- P.75.76, 79.8 338.48 Designation: An emplacement composed of: (a) one part of lot 75 upon the cadaster of the Parish of St.Colomban, bounded in front to the west and to the north by the division line of the Parish of St.Colomban and St.Jeruzalem and by the public road, in rear to the southeast by a part of lot 75, from one side to the west southwest by the part of No.76 hereinafter described and from the other side to the east-northeast by lot No.74; (b) one part of lot 76 on the same cadaster, bounded in front to the west by the division line between the Parish of St.Colomban and St.Jeruzalem, in rear to the south-southeast by a part hereinafter described and by part of No.78, and from the other side to the east-northeast by lot 75 hereinabove described ; (c) one part of lot No.79 upon cadaster of the Pariah of St.Colomban, bounded 842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, £9 janvier X97£, 101- année, n\" l Montant Nom du propriétaire Numéro de lots dû Name of owner Number of lote Amount due Jeruzalem, à l'est nord-est par la partie du No 76 ci-dessus décrite et au sud par le No 78.Leslie, Budai.Demers, John Succession.Désignation: Mesurant 1 arpent de largeur par 240 pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, borné devant par la Côte St-Paul, en arrière par le résidu du lot 192, côté est et ouest par le résidu du lot 192.Trottier.Marcel.Désignation : Mesurant 50 pieds de largeur par 90 pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, borné devant par une rue, à l'arrière et des deux côtés par le résidu du lot 195.to the west by the division line of the Parish of St.Colomban and St.Jeruzalem, to the east-northeast by the part of lot No.76 hereinabove described and to the south by lot No.78.71-144.8 69.81 P.192.194.39 Designation: Measuring 1 arpent of width by 240 feet of depth, English measure and more or less, bounded in front by Côte St.Paul, in rear bythe residue of lot 192, east and west side by the residue of lot 192.P.195.118.64 Designation: Measuring 50 feet of width by 90 feet of depth, bounded in front by a street, to the rear and to the two sides hy the residue of lot 195.Shapiro.Albert & Cobrin, Rubin.Désignation: Lot 272 moins à distraire partie appartenant à Dame Myrtle Margaret Stinson.Lots 273 et 274 moins à distraire partie appartenant à Dame Myrtle Margaret Stinson.P.272, 273, 274.270.43 Designation : Lot 272 less to be distracted part belonging to Dame Myrtle Margaret Stinson.Lot 273 and 274 less to be distracted part belonging to Dame Myrtle Margaret Stinson.Commission scolaire catholique de Ste-Marthe-sur-le-Lac \u2014 Catholic School Commission of Ste Marthe-sur-le-Lac Cadastre de la paroisse de St-Eustache \u2014 Cadastre of the Parish of St.Eustache Bajohr, Eugénie Mme Vve.Bologna, Eddy.Briseoois, Richard.Bergeron, Jacques.Champagne, Bernard/George Pencz.Di Giulio.Salvatore.Ethier.Emile.Geary, Marylin Mile.Gonthier, Raymond & Al.Infante.Joseph.Landry, Benoit.Moskàliuk, Nicholas Suce.Nadon, Claude.Roger, Gaston, Mme Vve.Roger, Stanislas Succ.Showier, Douglas.Tessier.Leopold.Désignation 136-P.290: mesurant 5 pieds de largeur par toute la profondeur dudit lot, borné en front par la 20ième Avenue, en arrière par le lot 136-180, d'un côté par le lot 136-291 et de l'autre côté par le résidu du lot 136-290.133-161,162,163 .8 134.64 141-107,108 .28.28 153-175.118.32 150-355,356.113.74 156-85,86.160.37 136-81.108.31 182-14.25.00 155-91.196.10 155-145.124.37 130-7,8.155.72 133-202.76.64 136-133, 134, 135, 136,136-137, 138.395.27 133-186, 186, 187.158.02 153-87.138.96 133-130, 131.132.150 20 160-149,150.17 49 136-290 P.291, 292.305!72 Designation: Measuring 6 feet of width by the whole depth of said lot, bounded in front by 20th Avenue, in rear by lot 136-180, on one side by lot 136-291 and to the other side by the residue of lot 136-290.Trépanier, Paul-André.Vaillancourt, Aimé.Ligue des Propriétaires de St^Eustache Ouest.Ligue des Propriétaires de St-Eustache Ouest.Désignation P.136: borné à l'ouest par l'avenue de la Baie, à l'est par l'avenue du Lac, au nord par l'avenue du Parc et au sud par le bord de l'eau.Motel Deux-Montagnes ltée.Désignation: mesurant 90 pieds de largeur en front le long du Chemin Oka, 86, en arrière par 105 pieds de profondeur dans la ligne nord-est et 153 dans la ligne sud-ouest, mesure anglaise et plus ou moins; borné en front par le chemin Oka, en arrière et du côté sud-ouest par des parties du lot 153 et au nord-ouest par le lot 152.158-49,80.81.340 13 131-181.::::::; \"5:8 135-606, 607, 608, 509, 610, 611.;.220 46 p- !36.699.28 Designation: Bounded to the west by Avenue of the Baie, to the east by the Avenue of the lake, to the north by the Avenue of the Park and to the south by the edge of the water.p-153.1,381.19 Designation: Measuring 90 feet of width in front along Oka road.86 in rear, by 105 feet of depth in its northeast line and 153 feet in its southwest line, English measure and more or less; bounded m front by Chemin Oka, in rear and to the southwest side by part of lot 153, and to the northwest by lot 162. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January £9, 197£, Vol.101, No.i 843 Commission scolaire de St-Eustache \u2014 School Commission of St.Eustache Cadastre de la paroisse de St-Eustache \u2014 Cadastre of the parish of St.Eustache Nom du propriétaire Name of owner Giguère, Marguerite Mme.Hébert, Roland.Hébert, Roland.Verner, Maurice.Delvecchio, Pierre.Huot, Jacques.Gauthier.André.Gradek, Jean.Gradek.Jean.Gradek, Jean.Gradek, Jean.Gradek, Jean.Gradek, Jean/Ornstein Stiffi M.Gradek, Jean/Ornstein Stiffi M.Gradek, Jean/Ornstein Stiffi M.Filteau, Yvon.Sauriol, Germaine Mme.Me Dougall.Yvon.Lapierre, Guy.Bousquet, Raymond.Perras J.W.,.Désignation: Lot 29 moins à distraire partie vendue à Gaétan Lamoureux suivant acte enregistré à Deux-Montagnes, sous le No 105012, et partie vendue à Dame Gabrielle Messier suivant acte enregistré à Deux-Montagnes, sous le No 68320.Cochionero, Philippe.Richer, Gérard.Deputter, Yvan.Désignation P.379: mesurant 187 pieds de largeur en front et en arrière, 96.83' pieds de profondeur dans sa ligne est, 99.08' pieds dans sa ligne ouest, mesure anglaise et plus ou moins, borné en front par la route 8, à l'est par partie du lot 379, en arrière par le lot 513-2 et Ù l'ouest par des parties des lots 377 et 378.Dagenais, Denise, Mme L.Séguin, Zéphirin, Mme (Denise Bigraa).Aubé, Guy.-.Carrier, Léonile.Placements Nuckle Inc.Villemure.Roger.Désignation : mesurant 50' de largeur par 86' de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, borné en front par le chemin de réserve qui part de la Grande Côte et va à la rivière Jésus en arrière par Wilfrid Noël ou représentants, d'un côté vers le sud par Eddie Dolan et de l'autre côté vers le nord par Albert Montambault, P.du 31.Desrochers, Roger., Stonehavens Land Dev.Inc.Stiller.Walter.Domaine du Lac Guilbault.Huberman, Philippe.Nu Way Investments Corp.Ltd.Désignation: mesurant environ 43 arpents en superficie, borné en front à l'est partie par le rang du Petit St-Charles.partie par le lot de Raoul Piché, en arrière à l'ouest par Aidas Labelle, lot 456, d'un côté au sud par le trait carré du No 457, P.457 de R.Giroux, 458 de J.G.Touchette.459 de Hervé Touchette, 460 de A.Bélisle et P.462 de S.Labelle.Montant Numéro de lots dû Number of lots Amount duo 1-167.168.S 899.91 2-28.566.70 2-29.98.73 3-178 .801.09 P.3-180.851.90 25-114.694.88 42-20 .657.49 236-3 .609.05 236-2-1.108.12 230-2-2 .6.08 236-2-3 .6.08 236-2-4 .6.08 236-19 .6.08 236-20.6.08 236-21.5.08 26-45 .804.48 26-54.641,62 26-130.1,063.83 27-64 .758.01 28-53,64 .615.22 29-P.1.654.61 Designation: Lot 29 less to be distracted part sold according to deed registered at Deux-Montagnes under No.105012, and part sold according to deed registered at Deux-Montagnes under No.68320.30-21.467.43 31-43 .800.52 513-2, 4 P.379.1.042.23 Designation P.379: Measuring 187 feet of width in front and in rear, 96.83 feet of depth in its east line.99.08 feet in its west line, English measure more or less, bounded in front by route No.8, to the east by part of lot 379, in rear by lot 513-2 and at west by parts of lots 377 and 378.501-3.669.36 278-101,60-92.3,376.36 511-28 .868.32 288-159.737.10 60-20 .467.76 P.31.638.24 Designation : Measuring 50' of width by 85' of depth, English measure more or less, bounded in front by the road which starts from Grande Côte and goes to Jesus River, in rear by Wilfrid Noël or representatives, from one side to the south by Eddie Dolan and to the other side to the north by Albert Montambault.P.of 31.74 (Village St-Eustache).1.256 34 399 .8 357.88 448-16 .334.49 214-3.954.30 399 .583.27 P.451.392.61 Designation: measuring more or less 43 arpents of superficial area, bounded in front to the east part by the range of Petit St.Charles, part by lot to Raoul Piché, in rear to the west by A.Labelle, lot 456, from one side to the south by trait carré of No.457, P.457 of R.Giroux, 458 of J.G.Touchette, 459 of H.Touchette, 460 of A.Belisle and P.462 of S.Labelle.Cadastre de la paroisse do St-Augustin \u2014 Cadaster of the parish of St.Augustin 844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i- année, n° k Municipalité du Village de St-Placide \u2014 Municipality of the Village of St.Placide Montant Nom du propriétaire Numéro de lote dû Name of owner Number of lots Amount due Dubreuil Romuald et Grégoire J.Adélard.Désignation: mesurant 45' de largeur au chemin et se trouvant de forme irrégulière, borné devant par le chemin public, d'un côté par un ruisseau, et de l'autre par les emplacements de ia rue St-Charles Borromée et en arrière par Adrien Dubreuil et autres.P.45-46.8 70.72 Designation: Measuring 45' of width in front and being of irregular form, bounded in front by the public road, from one side by a creek and the other by the emplacements of St.Charles Borromée and in rear by Adrien Dubreuil and others.Paroisse de St-Eustache \u2014 Parish of St.Euatache Gravel, Gérard.Théroux, J.P.Viau, Real.Tessier, Gaétan.Daiglc, Louis.Daigle, Louis.Bérard, André.Boudard, Anne-Marie.Désignation : ayant front sur le rang nord de la Petite Rivière et situé au sud dudit rang et compris entre les bornes suivantes: au nord en front par le rang de la Petite Rivière, en arrière vers le sud, par la rivière du chêne, d'un côté a l'est par le No 333 et de l'autre côté à l'ouest par le lot de H.Charrette.- Gougoan, Joseph.Désignation: dans le rang de la Grande Côte mesurant 100' de largeur par 87' de profondeur, borné au nord-est par une rue projetée, au sud-est par P.31, en arrière par P.36, et au nord-ouest par P.31, sis à 239' de la rivière des Mille Iles.Al vin Corporation.Désignation: ayant front sur la Côte Cachée, mesurant 925' de largeur en front dans sa ligne nord-ouest et 455' de profondeur dans sa ligne sud-ouest, borné en front par la Côte cachée, en arrière au sud-est par la rivière Chicot, d'un coté au nord-est par une partie du No 30, et de l'autre côté au Bud-ouest par la 20ième Avenue.1-71.S 405.93 1-332.82.41 2-14.74.98 26-117.805.69 31-62.180.77 31-63.180.06 53-443.7.00 P.334 .281.40 Designation: fronting on range north of Petite Rivière and situated to the south of said range and comprised into the boundaries following: to the north by range of Petite Rivière, in rear to the south by river Du Chêne, from one side to the east by No.333 and to the other side by lot of H.Charette to the west.P.31.190.26 Designation: in the range of Grande Cote, measuring 100' feet of width by 87' of depth, bounded to the northeast by a projected road, to the southeast by P.31, in rear by P.36, and to the northwest by P.31, situated at 239' from Rivière des Mille Iles.P.30.33.424.43.33 Designation: fronting on Côte Cachée, measuring 925' of width in front in its northwest line, and 455' of depth in its southwest line, bounded in front by Côte Cachée, in rear to the southeast by Chicot River, from one side to the northeast by part of No.30, and to the other side to the southwest by 20th Avenue.Commission scolaire protestante du Lac des Deux-Montagnes \u2014 Lake of Two Mountains Protestant School Commission Cadastre de la paroisse de St-Eustache \u2014 Cadastre of the parish of St.Eustache Tremblay, Gilbert.Désignation: mesurant 60 pieds de largeur par cent pieds de profondeur, mesure anglaise, borné en front par la 17ième Avenue, en arrière parle résidu du lot 272 du 88, au sud-est par le No 88-271, et au nord-ouest par le No 88.160.Worall, Joseph.Danis, Madeleine Mrs.Désignation: 69-2 et 3, moins partie il distraire de 72 pieds de longueur par 31.5 du côté est et 30 pieds du côté ouest de largeur.69.4, moins partie à distraire de 33 pieds dans ligne sud-est, 31.3 pieds dans ligne sud-est, 20.7 dans ligne nord-ouest, 12.3 dans autre ligne nord-ouest, 17.8 dans ligne sud-ouest et 13.5 dans autre ligne sud-ouest.Mac Donald.Earl R.Café Du Domaine Inc.Désignation P.284: mesurant 389\" en front, 381.3'en arrière, par 124 pieds dans ligne sud-est.et 120.8 pieds dans ligne nord- 88-P.272.$ 477.31 Designation : Measuring 60 feet of width by 100 feet of depth, English measure, bounded in front by 17th Avenue, in rear by the residue of lot 272 of 88, to the southeast by lot No.88-271, and to the northwest by lot No.88-160.79-31.627.56 69-P.2;P.3;P.4,5,6.1,421.04 Designation: 69-2 and 3, less to be deducted part of 72 feet of depth by 31.3 feet from cast side and 30 feet from west side of width.69-4, less part to be distracted of 33 feet in its southeast line, 31.3 in its southeast line.20.7 in.its northwest line.12.3 in its other northwest line, 17.8 in its southwest line and 13.5 in an other southwest line.88-3.88-4-1.284-52.P.284.830.80 2.910.67 Designation: P.284: Measuring 389' in front.381.3' in rear, by 124' in its southeast line, and 120.8' in its northwest line, * QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.k 845 Nom du propriétaire Name of owner Numéro de lots Number of lots Montant dû Amount due ouest, borné en front par Boul.Sauvé, en arrière parrésidu du 284, au nord-ouest par partie du 411, et au sud-est par No 284-62.bounded in front by Boul.Sauvé, in rear by residue of 284, to the northwest by part of 411, and to the southeast by No.284-52.Entreprises D.F.Leburn.Vinieris, George.Duluth Auto Parts.Désignation: mesurant 300' de largeur par 410' de profondeur, mesure anglaise, borné en front par le Boul.Sauvé, en arrière par lot 412, d'un côté par le lot de A.Lahaie, et de l'autre côté par le résidu du 411.138-1.S 66.67 325-178.34.10 P.411.690.80 Designation: Measuring 300' of width by 400' of depth, English measure, bounded in front by Boul.Sauvé, in rear by lot 412, from one side by lot of A.Lahaie, and from the other side by residue of 411.Montreal Land & Housing.Bowden, Muriel Mrs.Motel Deux-Montagnes Ltd.Désignation: mesurant 90' de largeur en front, 86' de largeur en arrière, par une profondeur de 105 pieds dans sa ligne nord-est, 153' dans sa ligne sud-ouest, et borné en front par le chemin Oka, en arrière et au sud-ouest par des parties de 163, et au nord-ouest par le No 152.438.201.71 135-467,458,459.145.48 P.163.2,497.98 Designation: Measuring 90' of width in front, 86' of width in rear, by 105' of depth in its northeast line, and of 163' in its southwest line and bounded in front by chemin Oka, in rear and to the southwest by parts of lot 153, and to the northwest by No.152.Val des Sables Ltd.150-108,109,110,111,112; 168-68,69,70,71, 3,029.37 158-72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 158-87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.94.95, 96, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135.136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 158-147, 148; 158-97,98.99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 150, 151, 152, 153, 154, 155.156, 157, 158-158.159; 158-114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169; 148-P.181, 182.Désignation 148-P.181 et 182, 148-P.181 : borné au nord par No 182, au sud par P.181 du C.N.R., à l'est par le No 148-357, à l'ouest par une ligne se croisant entre le No 182 et la partie du 181 du C.N.R.148-P.182: borné au nord par le No 148-183, au sud par une partie du No 181 et par une partie du 182 du C.N.R., à l'est par le No 148-357, à l'ouest par une partie du No 148-238 du C.N.R.Designation: 148-P.181 and 182: 148-P.181: bounded to the north by No.182, to the south by P.181 to the C.N.R., to the east by No.148-357, to the west by a line crossing between lot 182 and the part of 181 of the C.N.R.148-P.182: bounded to the north by No.148-183.to the south by a part of No.181 and by a part of No.182 of the C.N.R., to the east by No.148-357, to the west by a part of No.148-138 of the C.N.R.Val Des Sables Ltd.Désignation : borné au nord par le No 148-257, au sud partie par le No 255 et partie par P.266 du C.N.R., à l'est par P.148-584, à l'ouest par une partie du No 148-310.148-P.256.Designation: bounded to the north by No.148-257, to the south part by No.255 and part by P.256 of the C.N.R., to the east by P.148-584, to the west by a part of No.148-310.Val Des Sables Ltd.Désignation : mesurant 2 arpents et demi de largeur plus ou moins, sans garantie de mesure, situé entre le chemin d'Oka et la partie subdivisée du lot 158, borné en front par la route d'Oka, en arrière par d'autres partie du 158, d'un côté par le No 157 et l'autre côté par le No 159.P.158.Designation : Measuring 2 arpents and a half of width more or less, without guarantee, situated between Chemin Oka and subdivided part of No.158, bounded in front by Oka road, in rear by other parts of No.158, from one side by No.157, and the other side by No.159.Ent.Gerbex Inc.Désignation: mesurant 57' de largeur par 80' de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, borné en front par la 1ère Avenue en arrière par le lot de Dame J.Guilbau ou représentants, d'un côté par le lot de E.St-Pierre ou représentants et de l'autre côté par le lot de Dame Napoléon Judd ou représentants.P.117.1,119.64 Designation: Measuring 67' of width by 80' of depth, English measure more or less, bounded in front by 1st Avenue, in rear by lot of Dame J.Guilbau or representatives, from one'side by lot of E.St.Pierre or representatives, and to the other side by lot of Dame Napoléon Judd or representatives.En foi de quoi, je signe à Ste-Scholastique, ce sept In testimony whereof.I sign at Ste Scholastique, janvier 1972.this January seventh, 1972.Le secrétaire-trésorier, Gustave Thériault, Notary, 44029-3-2-o Gustave Thériault, notaire.44029-3-2-o Secretary-Treasurer. i 846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10 A' année, n° A Municipalité du comté de Richelieu Avis public est, par le présent, donné par le soussigné, J.Alphonse L'Heureux, secrétaire-trésorier du conseil municipal du comté de Richelieu, que JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS prochain (1972), à DIX heures de l'avant-midi, en la salle des séances du conseil de comté, au Palais de justice, à Sorel, je procéderai à la vente pour taxes, conformément aux dispositions du Code municipal, des immeubles ci-après décrits, à défaut de paiement préalable des taxes qui les affectent et des frais encourus, savoir: Municipality of the County of Richelieu Public notice is hereby given by the undersigned, J.-Alphonse L'Heureux, secretary-tresaurer of the Municipal Council of the County of Richelieu, that on THURSDAY, the NINTH day of MARCH next (1972), at TEN o'clock in the forenoon, in the County Council Hall, at the Court House, in Sorel, I will proceed to the sale for taxes, in conformity with the provisions of the Municipal Code, of the immoveables hereinafter described, in default of prior payment of taxes pertaining thereto and costs, to wit: Municipalité de la paroisse de Ste-Anne de Sorel \u2014 Municipality of the parish of St.Anne de Sorel \tTaxes\tTaxes\t Nom du propriétaire\tmunie.\tscol.\tTWot Name of owner\tMunie.\tSchool\t \ttaxes\ttaxes\t Bruyère, Yvette.S 91.89 $ 91.89 Maison érigée sur partie du lot No 9, acquise suivant acte A house erected on part of lot No.9, purchased according to enregistré sous le No 101,682, a deed registered under No.101,582.Chevalier, Jean-Paul.S 18.52 53.41 71.93 Chalet érigé sur le No 12.A chalet erected on No.12.Cormier, M.6.00 6.00 Chalet érigé sur partie du lot No 222.A chalet erected on part of lot No.222.Coté, Louis-Marie.78.81 78.81 Partie du lot No 107, telle que décrite en l'acte enregistré Part of lot No.107 as described in the deed registered under sous le No 137,012.No.137,012.Drouin.Arthur.6.60 6.60 Chalet érigé sur l'Ile de Grâce, sur terrain loué.A chalet erected on the Ile de Grâce, on rented ground.Fontaine, Antonio.10.01 10.01 Lot No 353, acquis suivant acte enregistré sous No 130,855.Lot No.353, purchased according to a deed registered under No.130,856.Faucher, Gilberte.102.20 102.20 Partie du lot No 107, telle que décrite en l'acte enregistré Part of lot No.107 as described in the deed registered under sous le No 130,623.No.130,523.Forcier, G.-A.100.44 100.45 Partie du lot No 148, telle quo décrite en l'acte enregistré Part of lot No.148 as described in the deed registered under sous le No 130,520.No.130,520.Guevremont, J.-Alfred.13.46 13 46 Lot No 361.Lot 361.Groulx.Jean-R.163.36 163.36 Partie du lot No 146.telle que décrite en l'acte de vente par Part of lot No.146 as described in the deed of sale bv Armand Proulx, enregistré sous le No 122,608.Armand Proulx, registered under No.122 508.Hendershott, Robert.299.34 i 299 34 Partie des lots Nos 20, 71 et 73, telle que décrite en l'acte Part of lot Nos.20.71 and 73 as described in the deed regis-enregistré sous le No 110,045.tered under No.110,046.regm- Jacques, Georges-A.20S.92 203 92 N.431-13 ptie____ 366-14.Ptie 364-1.397-4.429-4.Ptie 165-1.Ptie 545-1.307-1.308-3.312-3 Ptie.312-4 Ptie.312-5.313-3.314-5.174-2 ptie.Ptie 183-2.Ptie 168-2.Ptie 570.P.175-1.102-1, P.103-4.330-9.53-3.P.54-11.P.188.P.574-2.317-5.P.60-3.11-4.P.94-1.P.95-1.P.94-2.111-3.94-3 P.P.149-1.P.101-3.P.217-3.P.18-2.126-1.P.35.P.57-1.îiv.1er Ouest.Fox 1er Ouest.Fox 1er Ouest.Fox 1er Ouest.Fox 1er Ouest.Fox Nord de la Riv.Fox Nord du chemin Fox 1er Ouest.Fox 1er Ouest.1er Ouest.1er Ouest.1er Ouest.1er Ouest.1er Ouest.Nord de la Nord de la Nord de la Riv.Nord du chemin Nord de la Riv.Sud de la Riv.1er Ouest.Fox.Sud de la Riv.Fox.Sud de la Riv.Fox.Nord de la Riv.Fox.Nord du Chemin Fox.1er Ouest.Fox.Sud de la Riv.Fox.1er Est.Fox.Sud de la Riv.Fox.Sud de la Riv.Fox.Sud de la Riv.Sud de la Riv.Sud de la Riv.Sud de la Riv.Sud de la Riv.Nord de la Riv.1er Ouest.Fox Sud de la Riv.Fox 1er Est.Fox Sud de la Riv.Fox Fox.Fox.Fox.Fox.Fox.Fox.Fox.Fox.Fox.Fox.Fox.Fox.66.26\t$ 360\t84\tS 427\t10 \t60\t98\t50\t9S 18.25\t340\t32\t358\t57 96.37\t420\t26\t516\t62 1.45\t29\t49\t30\t94 21.23\t174\t10\t195\tS3 32.98\t349\t82\t382\tSO 106.06\t460\t30\t666\t3G 6.13\t224\t33\t230\t40 4.03\t135\t19\t139\t22 19.07\t159\t60\t178\t67 34.29\t214\t91\t249\t20 34.63\t283\t39\t318\t02 147.97\t563\t11\t711\tOS 11.10\t84\t22\t95\t32 129.22\t307\t73\t436\t96 166.00\t606\t42\t772\t42 6.25\t85\t00\t91\t25 6.63\t274\t18\t280\t81 15.76\t241\t94\t257\t70 30.69\t308\t05\t338\t74 \t142\t38\t142\t38 71.75\t366\t14\t437\tS9 11.38\t274\t46\t185\t84 28.49\t163\t60\t191\t99 22.67\t136\tSI\t159\t48 32.03\t400\t78\t432\t81 \t301\t78\t301\t78 13.76\t110\t57\t124\t33 139.27\t332\t48\t471\t76 Corporation municipale de Petite Vallée \u2014 Municipal Corporation of Petite Vallée Brousseau, Gaston.7-A-6.rang un.Cloridorme.Brousseau, Georges.7-A-16.rang un.Cloridorme.Côté, Bruno.6-A-3.rang un.Cloridorme.Côté, Mme Marie.____ 6-A-6.rang un.Cloridorme.Coulombe, Gérard.10-B.ptie.rang un.Cloridorme.Lebreux, Mme Robert.11-A-l, ll-A-2.rang un.Cloridorme.Lachance, Georges.10-A-2.rang un.Cloridorme.Lachance, Domicile.8-A-2.rang un.Cloridorme.$ 108.28 5.66 S 381.36 379.62 388.14 222.11 119.94 290.73 28.05 381.36 108.28 379.62 388.14 222.11 125.60 290.73 28.05 Municipalité de Grande Vallée \u2014 Municipality of Grande Vallée Bernatchez, Charles.Bernatchez, Emile.Bernatchez, Euchariste.Bernatchez, Jean-Baptiste.Beaudoin, Réjean.Côté, David A.Côté, Roger.Chicoine, Romain.Chicoine, Sylvio.Chrétien, Gonzague.Coulombe, Paul.Fournier, Félicien.Fournier, Emilien.Gagné, Philippe.104-3.Est Riv.Gde.Vallée.% 60.10 48-1.un.Gde.Vallée.$ 454.34 105-5.un Est.Gde.Vallée.41.84 399.95 47-2.un.Gde.Vallée.61.98 635.14 P.39-1.Ouest.Gde.Vallée.265.42 332.39 41-2.un.Gde.Vallée.31.18 P.108-3.Est.Gde.Vallée.47.88 455.48 22-1-2.Ouest.Gde.Vallée.232.86 736.50 24-2, 25-A-2.un.Gde.Vallée.21.80 592 36 ll-A-2.un.Gde.Vallée.130.85 7-2 et 13.Ouest.Gde.Vallée.61.95 75-3.Est.Gde.Vallée.180.20 460.81 1-A-l et 1-A-3-.un.Gde.Vallée.188.66 602.74 107-1 et 107-4.Est.Gde.Vallée.17.93 265.01 60.10 454.34 441.79 697.12 587.81 31.18 503.36 969.36 614.16 130.86 61.95 641.01 791.3Q 282.94 À QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January S9, 197S, Vol.lOi, No.I 949 Cant, ou Taxes Taxes Noms Numéro de lot Rang mun.munie.scol.Frais Total Names Lot number Range Township Munie.School Costs mun.taxes taxes Gagné, Jean.107-2.Est.Gde.Vallée.S 365.53 $ 365.53 Gagné, Clément.106-6.Est.Gde.Vallée.256.00 256.00 Gagné, Cyrias.P.99-1.Est.Gde.Vallée.40.22 40.22 Gagné.Gérard L.107-3.Est.Gde.Vallée.S 50.18 384.32 435.00 Francoeur, Mme Albert____ D-2.Est.Gde.Vallée.314.48 314.48 Lavoie.Gérard.23-6-6.Ouest.Gde.Vallée.243.41 828.09 1,071.50 Lavoie, Gédéon.D-l.un.Gde.Vallée.43.02 549.08 592.10 Huet, Mme Elzéar.17-2.un.Gde.Vallée.125.20 620.63 745.83 Minville, Bertrand.62,66-1,66-2.Ouest.C-l.Est.Gde.Vallée.116.75 584.92 701.67 Minville, Benjamin.6-2.un.Gde.Vallée.248.31 441.84 690.15 Minville, Augustin L.59-3.Ouest.Gde.Vallée.113.86 292.16 406.01 Minville, Amédé A.D-7.Est.Gde.Vallée.138.20 264.07 402.27 Mercier, Roland.106-1,106-3, 106-7.Est.Gde.Vallée.150.12 150.12 Mercier, Gervais.42-2.un.Gde.Vallée.26.34 26.34 Mercier, Antoine.106-2.Est.Gde.Vallée.75.48 75.48 Minville, François.43-A.Ouest.Gde.Vallée.62.86 128.94 191.80 Minville, Camille.P.67.Ouest.Gde.Vallée.18.00 519.65 637.65 Minville, Majorique.18-A-2.un.Gde.Vallée.288.33 350.09 638.42 Minville, Lionel.E-l.un.Gde.Vallée.50.59 382.76 433.35 Minville.Léonide.85-5.Est.Gde.Vallée.68.30 505.62 573.92 Minville, Léonard.B-l.Est.Gde.Vallée.3.32 52.77 56.09 Minville, Mme Julien.44-2.un.Gde.Vallée.49.07 388.55 437.62 Minville, Mme Horace.10-A-2.un.Gde.Vallée.373.95 521.01 894.96 Minville, Ulric.P.ll-B-2.un.Gde.Vallée.175.85 543.93 719.78 Minville, Roland.C-l.un.Gde.Vallée.27.92 27.92 Minville, Réal.63.Ouest.Gde.Vallée.196.32 158.43 354.75 Minville.Octave.P.45-1.Ouest.Gde.Vallée.155.34 326.82 482.16 Richard.Ephrem.8.Ouest.Gde.Vallée.338.27 338.27 Richard.Edouard.90-3.Est.Gde.Vallée.128.65 543.36 672.01 Richard.Antonio.37-2.un.Gde.Vallée.62.46 431.14 483.60 Richard Adhémar.B-2.Est.Gde.Vallée.575.48 575.48 Richard Adelme.27-4,28.Ouest.12-1.A.Gde.Vallée.12.23 709.24 721.47 Richard, Xavier.P.85-6.Est.Gde.Vallée.200.63 200.63 Richard, Romuald.9-B-3.un.Gde.Vallée.313.65 500.48 813.13 Richard, Leopold.31-2.un.Gde.Vallée.102.06 774.13 876.19 Richard, Léonard.89,90-1.Est.Gde.Vallée.748.18 748.18 Richard, Gervais.P.83.Est.Gde.Vallée.26.39 684.80 611.19 Percé, ce 8e jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44108-3-2-o E.O.Bodchard.Municipalité du Comté de Montmagny Avis public est donné par Gonzague Bélanger, notaire à Montmagny, secrétaire-trésorier de la Corporation du Comté de Montmagny, que les immeubles suivants seront vendus à l'enchère publique, selon le Code Municipal, JEUDI le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi, à la salle du Conseil de la cité de Montmagny, à l'Hôtel de Ville de Montmagny, pour taxes municipales, scolaires, rétributions mensuelles, rentes seigneuriales et répartitions d'Église, et les autres frais encourus non payés.Municipalité de Cap Saint-Ignace Un terrain étant le lot numéro quatre cent quatre-vingt et une partie du lot quatre cent soixante-dix-neuf (480 et ptie 479) au cadastre officiel de la paroisse de Cap St-Ignace, mesurant cent quatre-vingt-dix pieds (190') dans la ligne sud-est, deux cent trente pieds Percé, this 8th day of January, 1972.É.O.Bouchard, 44108-3-2-o Secretary-Treasurer.Municipality of the County of Montmagny Public notice is given by Gonzague Bélanger, notary at Montmagny, Secretary-Treasurer of the corporation of the county of Montmagny, that the following immoveables will be sold by public auction, according to the Municipal Code, on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, in the City of Montmagny Council Chamber, at the Montmagny City Hall, for municipal and school taxes, monthly payments, seigniorial rents and church assessments together with the other unpaid costs incurred.Municipality of Cap Saint Ignace A piece of land being lot number four hundred and eighty and a part of lot four hundred and seventy-nine (480 and part 479) of the official cadastre of the Parish of Cap St.Ignace measuring one hundred and ninety feet.(1.90') on the southeast line, two hundred and 950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1912, 104- année, n\" 4 (230') dans la ligne sud-ouest, cent quatre-vingt-cinq pieds (185') dans la ligne nord-ouest et cent quarante-quatre pieds (144') dans la ligne nord-est, lequel terrain est borné au sud-est au chemin public, au sud-ouest à la Rivière-des-Perdrix, au nord-ouest et au nord-est au terrain d'Alfred Fortin.Ce terrain appartient à M.Raymond Richard.\u2014 Taxes municipales: $1.88; taxes scolaires: $14.06.Un emplacement avec le chalet dessus construit, circonstances et dépendances, connu et désigné comme faisant partie du lot vingt-cinq et connu aussi comme étant le lot vingt-six (26 et ptie 25), du cadastre officiel de la paroisse de Cap St-Ignace, comté de Montmagny, borné au nord par le Fleuve St-Laurent, à l'est à Suce.J.Albert Fournier, au sud par le chemin public, à l'ouest à Lucien Fortin, ledit terrain mesurant deux cent vingt-sept pieds (227') de front du côté sud, mesure anglaise.Cet immeuble appartient à M.Jacques Revelin.\u2014 Taxes municipales: $57.55; taxes scolaires: $147.39.Municipalité de Berthier-en-Bas Un terrain faisant partie du lot numéro cinq (ptie 5) au cadastre officiel de la paroisse de Berthier-en-Bas, borné au nord au Fleuve St-Laurent, au nord-est à Réal Lavergne ou représentants, au sud au chemin public et au sud-ouest à Xavier Bouffard, sauf à distraire de ce terrain une partie vendue à M.Jacques Coulombe, tel qu'il appert à l'enregistrement No 89,636.Cet immeuble appartient à M.Fernand Chabot.\u2014 Taxes municipales: $19.42; taxes scolaires: $52.25.Un terrain faisant partie du lot numéro seize (ptie 16) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Berthier-en-Bas, Cté Montmagny, mesurant cinquante pieds (50') de largeur sur une profondeur de deux cents pieds (200') mesure anglaise; borné vers le nord au Fleuve St-Laurent, à l'est à Ludger Lagacé, au sud à Edouard Hoffman, à l'ouest à Zéphirin Sircis, avec un droit de passage dans un chemin de sortie situé en front dudit emplacement pour communiquer au chemin public.Cet immeuble appartient à Gaston Sirois.\u2014 Taxes municipales: $11.17.Municipalité de Sainte-Apolline Le lot numéro vingt-quatre (24) rang II, du Canton de Talon appartenant à Joseph Bissonnette et sujet aux droits de la Couronne.\u2014 Taxes municipales: S30.38; taxes scolaires: $58.27.Un terrain à prendre et à distraire du lot numéro treize (ptie 13), Rang A, du Canton Bourdages, mesurant soixante et onze pieds (71') de front, le long du chemin sur une profondeur de quatre-vingt pieds (80'), borné au nord à un terrain appartenant à René Fer-land, à l'ouest à la route, à l'est à Emmanuel Richard et au sud à la Couronne, sujet aux servitudes pouvant affecter ledit terrain.Ce terrain appartient à M.J.Ulfranc Bouchard.\u2014 Taxes municipales: $19.16; taxes scolaires: $22.20.Un terrain faisant partie des lots numéros six et sept (pties 6 et 7) au cadastre officiel du rang 10, du Canton thirty feet (230') on the southwest line, one hundred and eighty-five feet (185') on the northwest line and one hundred and forty-four feet (144') on the northeast line, which land is bounded on the southeast by the public road, on the southwest by Rivière-des-Perdrix, on the northwest and northeast by the land of Alfred Fortin.This piece of land belongs to Mr.Raymond Richard.\u2014 Municipal taxes: $1.88; school taxes: $14.06.An emplacement with a chalet constructed thereon, circumstances and dependencies, known and designated as being part of lot twenty-five and also known as being lot twenty-six (26 and part 25), of the official cadastre of the Parish of Cap St.Ignace, County of Montmagny, bounded on the north by the St.Lawrence River, on the east by the estate of J.Albert Fournier, on the south by the public road, on the west by Lucien Fortin, the said land measuring two hundred and twenty-seven feet (227') in front on the south side, English measure.This immoveable belongs to Mr.Jacques Revelin.\u2014 Municipal taxes: $57.55; school taxes: $147.39.Municipality of Berthier-cn-Bas A piece of land being part of lot number five (P.5) on the official cadastre of the Parish of Berthier-en-Bas, bounded on the north by the St.Lawrence River, on the northeast by Real Lavergne or representatives, on the south by the public road and on the southwest by Xavier Bouffard, save and to withdraw from this land, a part sold to Mr.Jacques Coulombe, as appears in registration No.89,686.This immoveable belongs to Mr.Fernand Chabot.\u2014Municipal taxes: $19.42; school taxes: $52.25.A piece of land being part of lot number sixteen (Pt.16) on the official plan and book of reference of the Parish of Berthier-en-Bas, County of Montmagny, measuring fifty feet (50') in width by a depth of two hundred feet (200') English measure, bounded on the north by the St.Lawrence River, on the east by Ludger Lagacé, on the south by Edouard Hoffman, on the west by Zéphirin Sirois, with a right of way on an exit road situated in front of the said emplacement communicating with the public road.This immoveable belongs to Gaston Sirois.\u2014 Municipal taxes: $11.17.Municipality of St.Apolline Lot number twenty-four (24) Range II of the Township of Talon belonging to Joseph Bissonnette and subject to the rights of the Crown.\u2014Municipal taxes: $30.38; school taxes: $58.27.A piece of land to be taken and withdrawn from lot number thirteen (Pt.13), Range A of the Township of Bourdages, measuring seventy-one feet (71') in front along the road by a depth of eighty feet (80'), bounded on the north by a piece of land belonging to René Ferland, on the west by the highway, on the east by Emmanuel Ricard and on the south by the Crown, subject to servitudes affecting the said land.This land belongs to Mr.J.Ulfranc Bouchard \u2014Municipal taxes: $19.16; school taxes: $22.20.A piece of land being part of lots numbers six and seven (Pta.6 and 7) of the official cadastre of Range 10 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101,.No.I 951 Bourdages, circonstances et dépendances, mesurant trente-cinq arpents en superficie, borné au nord-ouest au terrain de Napoléon Gagné, au nord-est au terrain de Raymond Pelletier, au sud-est à Jean-Léon Desrosiers et Marcel St-Hilaire, et au sud-ouest à Jean-Léon Desrosiers.Cet immeuble appartient à M.Donald Boucher.\u2014 Taxes municipales: S14.86; taxes scolaires: $18.39.Le lot numéro vingt-cinq (25) rang II, du Canton Talon appartenant à Fernand Chabot, sujet aux droits de la Couronne.\u2014 Taxes municipales: $14.86; taxes scolaires: $35.76.Tous les droits que M.Lucien Gagné peut avoir sur un emplacement situé à Ste-Apolline et pris à même le lot numéro trente-neuf (39), rang I, du Canton de Talon; borné comme suit: au nord-ouest au chemin public, au nord-est au lot 40, au sud-est et sud-ouest au résidu du lot 39 (Charles Gagné) appartenant à M.Lucien Gagné.\u2014 Taxes municipales: $30.38; taxes scolaires: $59.28.Un terrain mesurant quatre arpents et quatre perches du nord au sud sur environ quatre arpents de l'est à l'ouest; borné au nord et au nord-est par Price Brothers, au sud à Désiré Bernier, au sud-ouest à la route publique, avec bâtisse, lequel terrain est connu comme faisant partie du lot numéro vingt-six (ptie 26), rang A du Canton de Bourdages et sujet aux droits de la Couronne.Cet immeuble appartient à M.Gérard Thibault.-\u2014Taxes municipales: $22.10; taxes scolaires: $45.52.La partie nord du lot numéro dix-neuf (ptie nord 19), rang B, du Canton de Bourdages appartenant à un inconnu.\u2014 Taxes municipales: $91.47; taxes scolaires: $163.70.Municipalité de Sainte-Euphémie Un terrain mesurant cent vingt pieds (120') de front par deux cents pieds (200') de profondeur, borné à l'est à Eugène Biais, à l'ouest et au nord à Philippe Biais, au sud au chemin public, connu et désigné comme faisant partie du lot numéro dix (ptie 10), rang I sud-est du Canton d'Armagh annexé à Montminy, appartenant à Roger Girard.\u2014 Taxes municipales: $6.03; taxes scolaires: $8.80.Donné à Montmagny, ce 10e jour de janvier 1972.Le secrétaire, 44112-3-2-0 Gonzague Bélanger.of the Township of Bourdages, circumstances and dependencies, containing thirty-five arpents, bounded on the northwest by the land of Napoléon Gagné, on the northeast by the land of Raymond Pelletier, on the southeast by Jean-Léon Desrosiers, and Marcel St-Hilaire, and on the southwest by Jean-Léon Desrosiers.This immoveable belongs to Mr.Donald Boucher.\u2014 Municipal taxes: $14.86; school taxes: $18.39.Lot number twenty-five (25) Range II of the Township of Talon belonging to Fernand Chabot, subject to the rights of the Crown.Municipal taxes: $14.86; school taxes: $35.76.All rights belonging to Mr.Lucien Gagné on an emplacement situated at St.Apolline and taken from lot number thirty-nine (39), Range I of the Township of Talon, bounded as follows: on the northwest by the public road, on the northeast by lot 40, on the southeast and south-west by the remainder of lot 39 (Charles Gagné) belonging to Mr.Lucien Gagné.\u2014 Municipal Uxes: $30.38; school taxes: $59.28.A piece of land measuring four arpents and four perches from north to south by about four arpents from east to west, bounded on the north and northeast by Price Brothers, on the south by Désiré Bernier, on the southwest by the public highway, with buildings, the said land is known as being part of lot number twenty-six (Pt.26), Range A of the Township of Bourdages and subject to the rights of the Crown.This immoveable belongs to Mr.Gérard Thibault.\u2014 Municipal taxes: $22.10; school taxes: $45.52.The northern part of lot number nineteen (north Pt.19), Range B of the Township of Bourdages belonging to an unknown.\u2014 Municipal taxes: $91.47; school taxes: $163.70.Municipality of St.Euphémie A piece of land measuring one hundred and twenty feet (120') in front by two hundred feet (200') in depth, bounded on the east by Eugène Biais, on the west and north by Philippe Biais, on the south by the public road, known and described as being part of lot number ten (Pt.10), Range 1, southeast of the Township of Armagh annexed to Montminy, belonging to Roger Girard.\u2014 Municipal taxes: $6.03; school taxes: $8.80.Given in Montmagny, this 10th day of January, 1972.Gonzague Bélanger, 44112-3-2 Secretary.Municipalité du comté de Napierville Avis public est par les présentes donné par M.Yves Dupont, secrétaire-trésorier, que les immeubles ci-dessous mentionnés seront vendus à l'enchère publique, au village de Napierville, au lieu où le conseil de comté tient ses sessions dans l'Édifice du comté de Napierville, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi, à défaut de paiement des taxes auxquelles ils sont affectés et des frais encourus.Municipality of the County of NapierviUe Public notice is hereby given by Mr.Yves Dupont, Secretary-Treasurer, that the immoveables hereunder mentioned will be sold by public auction in the Village of Napierville at the County Council Hall in the County of Napierville Building, on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, in default of payment taxes thereon and costs incurred. 952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° A Municipalité et cadastre de la paroisse de St-Rémi Municipality and cadastre of the Parish of St^Rémi Les immeubles suivant apparaissant comme appartenant à \u2014 The following immoveables, property of: Noms Names Superficie Area No cadastre Cadastral No.Taxes munie.Munie, taxes Taxes scolaire School taxes Intérêt Interest Total Beaudet.Gérard.53,821 p.c.P-298.$ 106.21 S 14.36 $ 120.57 Bourelle.Rolland.75 arp.c.391.508.36 5.16 513.52 Bourque, Hervé.22,816 p.c.P-298.199.07 9.49 208 56 Prud'Homme.Mme Jeanne.4,977 p.c.212-54 .343.64 6.74 350.38 Guay, Halley (succession-estate).547.3 p.c.212-P95.S 12.35 3.94 3.24 19.53 Municipalité et cadastre du village de Napierville Municipality and cadastre of the Village of Napierville L'immeuble suivant apparaissant comme appartenant à \u2014 The following immoveable, property of: Suce.Clément Boutin.P-341.Ladite partie du lot numéro trois oent quarante et un étant un emplacement ayant front rue St-Martin, connue et désignée comme faisant partie du lot numéro trois cent quarante et un (Ptie 341) du cadastre du village de Napierville, comté de Napierville, et bornée comme suit: vers l'ouest par le terrain de Délies Bissonnette ou représentants, vers l'est par le terrain de Alexandre Deragon ou représentants partie du lot No 341, au nord par la rue St-Martin et en arriére par les emplacements de la rue St-Alexandre.A distraire toutefois de cette partie la partie adjugée à Clovis Bourgeois suivant acte enregistré à Napierville No 49790.S 24.14 % 103.85 8 25.43 S 153.42 The said part of lot number three hundred and forty-one being an emplacement fronting on St.Martin Street, known and described as being part oflot number three hundred and forty-one (Pt.341) of the cadastre of the Village of Napierville, County of Napierville, bounded as follows : on the west by the land of Délies Bissonnette or representatives, on the east by the land of Alexandre Deragon or representatives and part of lot No.341, on the north by St.Martin Street and in the rear by the emplacements on St.Alexandre Street.Save and to withdraw however from this part, the part granted to Clovis Bourgeois according to the deed registered at Napierville, No.49790.Municipalité et cadastre de la paroisse de St-Patrice-de-Sherrington Municipality and cadastre of the Parish of St.Patrice-de-Sherrington L'immeuble suivant apparaissant comme appartenant à \u2014 The following immoveable, property of: Besser, Harold.173 arp.122.P-123, 125.126, 127.27.77 S 243.06 S 18.25 S 289.08 La superficie des immeubles ci-dessus mentionnés est plus ou moins et sans garantie.Donné à Napierville, ce 6 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44113-3-2-0 Yves Dupont.The area of the immoveables hereinabove mentioned is more or less and without guarantee.Given at Napierville, this January 6, 1972.Yves Dupont, 44113-3-2 Secretary-Treasurer.Municipalité du comté de Saint-Maurice Avis public est par les présentes donné par le soussigné, J.Armand Pellerin, secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, que les immeubles ci-après décrits seront vendus à l'enchère publique, en la salle publique du village d'Yamachiche, située au sous-sol de l'église, entrée par la porte No 3, lieu où le conseil dudit comté tient ses sessions, que JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi, pour taxes municipales, scolaires et autres redevances, dues aux municipalités ci-dessous mentionnées à moins qu'elles ne soient payées avec les- frais encourus avant la vente.Municipality of the County of St.Maurice Public notice is hereby given by the undersigned, J.Armand Pellerin, Secretary-Treasurer of the aforesaid municipality, that the immovables hereinafter described will be sold by public auction, in the Public Auditorium of the Village of Yamachiche, situated in the basement of the church, entrance by door No.3, meeting place of the said County Council, on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for the municipal and school taxes and other dues owing to the municipalities mentioned below, unless they are paid, together with the costs incurred, prior to the sale. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1973, Vol.104, No.4 953 Municipalité de Saint-Boniface de Shawinigan \u2014 Municipality of Saint-Boniface de Shawinigan Nom Name\tLot No\tRang Range\tSuperficie Area\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tRép.église Church dues\tFrais Costs\tTotal \t406-16.407-70.\t8.\t17402'.\tS 7.00 1.30\tf 6.50 9.07\t\tS 2.30 2.10\tS 15.80 12.47 adresse inconnue-address unknown Fernand Mongrain.\t\t8.\t\t\t\t\t\t adresse inconnue-address unknown\t\t\t\t\t\t\t\t Municipalité de Saint-Êlie de Caxton \u2014 Municipality of Saint-Elie de Caxton\t\t\t\t\t\t\t\t adresse inconnue-address unknown\t20-72-\t7.\t1/10 arp.\tS 4.20\tf 12.18\t\t\tf 16.38 Municipalité Visitation Pointe-du-Lac \u2014 Municipality of Visitation Pointe-du-Lac\t\t\t\t\t\t\t\t Mme-Mrs.Bertrand Daigneault.\tP.105.\tvillage.\t\tS 7.20\tS 33.09\t8 8.00\t\tS 48.29 Municipalité de la paroisse de Sainte-Anne d'Yamachiche \u2014 Municipality of the parish of Sainte-Anne d'Yamachiche Armand Foucher, Shawinigan.Jean-Claude Gauthier, Yamachiche Léo-Paul Gélinas, Charette.Martial Gélinas,.R.2, Yamachiche.Camille Sauvageau, 1019 Ste-Angcle Trois-Rivières.P-45.P-47 SP1155.P.650.P.935.P.51.R.G.V.R.L.G.R.Commune R.G.tX arp.bât.-bldg.14 arp.\\i arp- X arp- S 1.08\tS 3.66\tS 7.50\t$ 0.96 10.00\t33.99\t124.00\t0.78 7.56\t21.96\t69.79\t1.80 17.45\t115.46\t\t1.32 10.93\t12.12\t6.00\t3.03 13.20 168.77 101.11 134.23 31.08 Donné à Yamachiche, ce lie jour de janvier 1972.44115-3-2-0 Le secrétaire-trésorier, J.Armand Pellerin.Given at Yamachiche, this 11th day of January, 1972.J.Armand Pellerin, 44115-3-2 Secretary-Treasurer.Municipalité du comté de Verchères Avis public est, par les présentes, donné par le soussigné Claude Geoffrion, secrétaire-trésorier de la municipalité du Comté de Verchères, que les terrains suivants, avec constructions y érigées, seront vendus à l'enchère publique, en la salle des sessions du Conseil municipal du Comté de Verchères, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi, pour les taxes et cotisations municipales, scolaires, intérêts accrus et charges, à moins que le tout n'ait été payé avant la vente, savoir: Municipality of the county of Verchères Public notice is hereby given by the undersigned, Claude Geoffrion, Secretary-Treasurer of the municipality of the County of Verchères, that the following lands with the buildings thereon erected will be sold by public auction, in the Council Room of the Municipal Council of the County of Verchères, 611 Marie-Victorin, Verchères, on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for the municipal and school taxes, interests accrued, costs and charges, unless the whole be paid before the sale, to wit: Municipalité de la Paroisse de Saint-Amable \u2014 Municipality of the Parish of Saint-Amable Nom du propriétaire\tNuméro du lot\tTaxes munie.\tTaxes scol.\tInt.et frais\tTotal Name of owner\tLot number\tMunie, taxes\tSchool taxes\tInt.and costs\t \t\t-£6.40\t____\t* 7.60.\t» .93.90 954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Nom du propriétaire Name of owner Numéro du lot Lot number Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Int.et frais Int.and costs Total Daigneault, Aimé.18 Rang C.Gemme, Conrad Mme-Mrs.P.209.Désignation P.209: borné en front par la rue David, d'un côté par la propriété de M.Raymond Dalpé, de l'autre côté par celle de Mme Desneiges Casavant, et en arrière par celle de Mme Aristide Gemme, mesurant un arpent de largeur sur une profondeur de 75 pieds, avec bâtisses.$ 142.55 $ 9.82 $ 152.37 .72.08 72.08 Description P.209 : bounded in front by David Street, on one eide'by the property of Raymond Dalpé, on the other side by the property of Mrs.Desneiges Casavant and to the rear by the pro-erty of Mrs.Aristide Gemme, measuring one arpent in width by a depth of 75 feet, with the buildings thereon erected.Gemme, Jean-Guy.P.205.Désignation P.205: borné en front par la rue Dupuy, des deux côtés et en arrière par la propriété de M.Ernest Bé-nard, avec bâtisses.84.40 9.91 94.31 Description P.205: bounded in front by Dupuy Street, on both sides and to the rear by the property of Ernest Bénard, with the buildings thereon erected.Gemme, Marcel (Emery) Suce, époux de P.181-4, P.182-4, P.183-15 feue Dame Marguerite McDuff.Désignation: lot ptie 181 subdivision No 4, lot ptie 182 subdivision No 4, lot ptie 183 subdivision No 15, borné en front par la rue Edmond, d'un côté par La propriété de M.Marius Gemme, de l'autre côté par celle de Jean-Paul Gemme, en arrière par celle de Jean-Louis Bénard, mesurant 75 pieds de largeur sur une profondeur de 125.80 pieds.Située à 434 rue Edmond (avec bâtisse).60.80 3.50 54.30 Description: lot pt.181 subdivision No.4, lot pt.182 subdivision No.4, lot pt.183 subdivision No.15, bounded in front by Edmond Street, on one side by the property of Marius Gemme, on the other side by the property of Jean-Paul Gemme, to the rear by the property of Jean-Louis Bénard, measuring 75 feet in width by a depth of 125.80 feet.Situated at 434 Edmond Street (with the building thereon erected).Gemme, Wilfrid.6 Rang A.Maskaleut, Roger.9 Rang B.Sansalone, Jean-Baptiste.P.205.Désignation P.205: borné en front par la rue Rémi, d'un côté par la propriété de Marius Messier, de l'autre côté et en arrière par la propriété de Ernest Bénard, mesurant 225 pieds par 75 pieds, avec bâtisse.80.90 5.77 86.67 .74.60 5.28 79.88 .14.40 2.12 16.52 Description P.205: bounded in front by Rémi Street, on one side by the property of Marius Messier, on the other side and in the rear by the property of Ernest Bénard, measuring 225 feet by 75 feet, with the buildings thereon erected.Municipalité de la Paroisse de Saint-Marc\t\u2014 Municipality of the Parish of Saint-Marc\t Beauchemin, Alcime.10-46-1.10-48____\t.S 78.67 S 443.52\t$ 622.19 Municipalité du Village de McMastervilIe \u2014\tMunicipality of the Village of McMastervilIe\t Aubut Construction.7-94,7-95.Bienvenu, Denis.18rl6.Perreault, Jean.19-83-P.29A, 19-P.19-P.80.Désignation : Un emplacement situé au Village de McMastervilIe, connu et désigné comme étant: A) partie du lot vingt-neuf A de la subdivision du lot numéro quatre-vingt-trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro dix-neuf (19-83 Partie 29A); B) l'extrémité nord-ouest de l'extrémité nord-est du lot numéro soixante-dix-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro dix-neuf (19-Ptie 78); et C) l'extrémité nord-ouest du lot numéro quatre-vingt de la subdivision officielle du lot originaire numéro dix-neuf (19-Ptie 80); mesurant ledit emplacement, cinquante-neuf pieds (59') à sa ligne sud-est, et quatre-vingt-dix pieds (90') à sa ligne sud-ouest, le tout mesure anglaise et plus ou moins, et borné comme suit: au nord-ouest par une rue de quarante pieds, mesure anglaise, étant partie dudit lot numéro 19-83-29A; au sud-est, par partie dudit lot numéro 19-80 restant au vendeur; du côté nord-est, partie par la rue Comtois étant le lot numéro 19-81 et partie par ladite rue portant le numéro 19-83-29A; et du côté sud-ouest, par parties des lots numéros 19-78, 19-79 et 19-83-29A appartenant à Hormidas Beauchemin.78, 21.91 S 583.00 139.96 624.62 664.29 9.68 S 171.55 27.67 652.29 59.32 1,306.61 Description: An emplacement situated in the Village of McMastervilIe, known and designated as being: (A) part of lot twenty-nine A of the subdivision of lot number eighty-three of the official subdivision of original lot number nineteen (19-83 Pt.29A); (B) the north-westerly and of the northeasterly end of lot number seventy-eight of the official subdivision of original lot number nineteen (19-Pt.78) ; and (C) the north-westerly end of lot number eighty of the official subdivision of original lot number nineteen (19-Pt.80); measuring said emplacement, fifty-nine feet (59') in its southeast line, and ninety feet (90') in its southwest line, English measure and more or less, and bounded as follows: to the northwest by a forty feet wide street, English measure being a part of said lot number 19-83-29A; to the southeast, by a part of said lot number 19-80 belonging to the vendor; on the northeast side partly by Comtois Street, being lot No.19-81, and partly by said street bearing number 19-83-29A; and on the southwest side by parts of lots numbers 19-78, 19-79 and 19-83-29A belonging to Hormidas Beauchemin. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10i, No.4 955 Municipalité de la Paroisse Saint-Mathieu de Beloeil \u2014 Municipality of the Parish of Saint-Mathieu de Beloeil \t\tTaxea\tTaxes\tInt.et\t Nom du propriétaire\tNuméro du lot\tmunie.\tscol.\tfrais\tTotal Name of owner\tLot number\tMunie, taxes\tSchool taxes\tInt.and costs\t Chapman.Bryson.313-30.Chapman, Bryson.316-42.Chapman, Bryson.316-40.Chapman.Bryson.316-41.Laporte, Léonard.286.Laporte, Léonard.296.Laporte.Léonard.407.P.408.P.406.Désignation 407, P.408: Un terrain partie en culture et partie en bois debout étant le lot numéro quatre cent sept et la moitié sud-ouest du lot numéro quatre cent huit (407 et 14 S.O.408) des plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Beloeil, situé dans la cinquième concession de ladite paroisse, contenant environ quatre arpents et demi de largeur sur environ neuf arpents de profondeur, borné en front, au sud-est, partie par le lot No 286 et partie par le No 287, en arrière, au nord-ouest, par les lots Nos 410, 409, 406.405.404 et 403.du côté nord-est par partie dudit lot No 408 appartenant à Emery Laporte, et du côté sud-ouest par le lot No 401, avec une cabane à sucre et tout l'agrcs de sucrerie; Désignation P.406: Une autre terre à bois située dans la cinquième concession de ladite paroisse, étant la partie sud-ouest du lot connu et désigné sur le plan et au livre de renvoi officiels de la paroisse de Beloeil sous le numéro quatre cent six (Ptie 406), contenant environ cinq huitièmes d'arpent de largeur par environ vingt et un arpents de profondeur, bornée en front, au sud-est, par le lot No.407, en arrière, au nord-ouest, par la sixième concession, du côté sud-ouest par le lot numéro 405, et du côté nord-est, par le résidu dudit lot numéro 406 appartenant à Emery Laporte, sans bâtisse.32.81 S\t3.38 S\t36.19 44.83\t5.27\t50.10 45.87\t5.48\t51.35 906.59\t15.58\t922.17 234.43\t7.20\t241.63 110.70\t3.31\t114.01 Perreault, Jean.372.Perreault, Jean.373, P.294.Désignation P.294: 1.Une lisière de terrain désignée au cadastre officiel de Beloeil comme la partie nord-ouest de la partie nord-est du lot originaire numéro deux cent quatre-vingt-quatorze (partie n.-o.de partie n.-e.de 294) mesurant douze pieds (12') de largeur, plus ou moins, mesure anglaise, sur toute la profondeur qui peut se trouver à partir du chemin du Ruisseau Nord à se rendre jusqu'à la limite nord-ouest dudit lot 294 ; et bornée comme suit : au sud-est, par le chemin du Ruisseau Nord; au nord-est, par la ligne de division entre les lots 293 et 294; au nord-ouest, par lalimite nord-ouest dudit lot 294 touchant aux lots 375 et 376; et au sud-ouest, partie par la lisière de terrain ci-après désignée et partie par le résidu nord-ouest dudit lot 294 appartenant à Marcel Provost ou représentants; 2.Une autre lisière de terrain, désignée au même cadastre comme la partie nord-ouest de la partie nord-ouest dudit lot numéro deux cent quatre-vingt-quatorze (partie n.-o.de partie n.-o.de 294), mesurant douze pieds (12') de largeur, plus ou moins, mesure anglaise, sur la profondeur qui peut se trouver à partir de la lisière de terrain ci-dessus désignée au paragraphe 1 à se rendre jusqu'à la ligne des lots 295 et 294 et s'élargissant à l'extrémité sud-ouest, pour former un terrain suffisamment large où une voiture automobile puisse opérer un virage complet; bornée comme suit: au nord-est, par la lisière de terrain ci-dessus désignée au paragraphe 1, au nord-ouest, par la limite nord-ouest du lot 294 touchant aux lots 374, 375 et 376; au sud-ouest, par la limite entre les lots numéros 294 et ?95; et au sud-est, par la partie sud-est de la partie nord-ouest dudit lot 294 appartenant à Marcel Provost ou représentants.Préfontaine, Roger.313-45, 315-17.Préfontaine, Roger.315-18.Description 407, P.408: a piece of land partly cultivated and partly wooded, being lot number four hundred and seven and the southwest half of lot number four hundred and eight (407 and S.W.« 408) of the official plan and book of reference of the parish of Beloeil, situated in the fifth concession of said parish, containing about four arpents and a half in width by about nine arpents in depth, bounded in front, to the southeast, partly by No.286 and partly by lot No.287, in the rear, to the northwest, by lots Nos.410, 409, 406, 405, 404 and 403, on the northeast side by part of said lot 408 belonging to Emery Laporte, and on the southwest side by lot No.410, with a sugar cabin thereon erected; Description P.406 : Another wooded land situated in the fifth concession of said parish, being the south-westerly part of lot known and designated on the plan and book of reference of the parish of Beloeil as being number four hundred and six (P.406).containing about five-eighths of an arpent in width by about twenty-one arpents in depth, bounded in front, to the southeast, by lot No.407, in the rear, to the northwest, by the sixth concession, on the southwest side by lot No.405, and on the northeast side, by the residue of lot 406 belonging to Emery Laporte, without construction.S 14.82 S 0.12 8 14.94 .60.72 0.37 61.09 Description P.294: 1.A parcel of land designated in the official cadastre of Beloeil as being the north-westerly part of the north-easterly part of original lot number two hundred and ninety-four (N.W.part of N.E.part of 294) measuring twelve feet (12') in width, more or less, by the depth that can be found from Ruisseau Nord Road until the north-westerly limit of said lot 294 ; and bounded as follows to the southeast, by Ruisseau Nord road; to the northeast, by the dividing line between lots 293 and 294 ; to the northwest, by the northwest limit of said lot 294 touching lots 375 and 376; and to the southwest, partly by the parcel of land described below and partly by the northwest residue of said lot 294 belonging to Marcel Provost or representatives; 2.Another parcel of land designated in the same cadastre as being the north-westerly part of the north-westerly part of said lot number two hundred and ninety-four (N.W.part of N.W.part of 294), measuring twelve feet (12') in width, more or less, English measure, by the depth that can be found from the parcel of land above described at paragraph 1 until the line of lots 295 and 294 and widening at the south-westerly end to from a piece of land wide enough to allow a car to operate a complete turn; bounded as follows; to the northeast by the above described parcel of land, to the northwest, by the northwest limit of lot 294 touching lots 374.375 and 376; to the southwest by the limit between lots numbers 294 and 295; and to the southeast by the south-easterly part of the northwesterly part of said lot 294 belonging to Marcel Provost or representatives.S 32.18 S 3.19 32.21 3.19 35.37 35.40 Donné à Verchères, ce 14 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44138-3-2-0 Claude Geoffrion.Given at Verchères, this 14th of January 1972.Claude Geoffrion, 44138-3-2-0 Secretary-Treasurer. 956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, ÎOA- année, 7t° l Municipalité du comté de Lotbinière Avis public vous est par le présent donné, par moi, soussigné, secrétaire-trésorier du Comté de Lotbinière, résidant à Ste-Croix, Lotbinière, P.Q., que JEUDI, le NEUVIÈME jour du mois de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi, au lieu ordinaire des sessions du Conseil de Comté, à Ste-Croix, au Bureau d'enregistrement du Comté de Lotbinière, les terrains ci-après désignés, seront vendus à l'enchère au rabais, à quiconque offrira de payer les montants des deniers à prélever, compris les frais encourus pour la moindre partie desdits terrains, qui seront mis à l'enchère, à défaut de paiement avant la vente, des taxes municipales et des cotisations scolaires, ci-après mentionnées et des frais encourus pour parvenir à ladite vente.Municipality of the county of Lotbinière Public notice is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer of the County of Lotbinière, residing at St.Croix, Lotbinière, P.Q., that on THURSDAY, the NINTH day of the month of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, in the County Council Chamber, County of Lotbinière, P.Q., St.Croix, the lands hereinafter described will be sold by public auction to cover non-payment of municipal and school taxes, including costs.Municipalité de St-Antoine de Tilly \u2014 Municipality of St-Antoine de Tilly Noms des propriétaires Numéros du cadastre Names of owners Cadastral numbers\t\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scolaires School taxes\t\tTotal \t.P-91.\t\t8 11.95 12.91\tS\t11.95 64.61 André Daigle.\t.236-8.236-9.234-A, 234-2, 236-7.\tS 61.70\t\t\t Laurent Fortier.\t.P-124-A.\t30.70\t169.02\t\t199.72 \t.P-144.\t169.88\t250.97\t\t420.85 \t.P-76, P-82.\t183.52\t\t\t183.52 408.30 38.74 Ernest Lier.\t.272, P-273.\t106.73\t301.57\t\t \t.P-267.\t\t9.66\t\t \t\t\t\t\t Municipalité de St-ApoUinaire \u2014 Municipality of St-Apollinaire\t\t\t\t\t \t.P-197.\t.S 6.02\tS 24.55\tS\t29.67 Emile Lambert.Emile Lambert.\t.482.\t97.00\t364.04 38.50\t\t461.04 46.66 \t\t\t\t\t Municipalité de Laurier Station \u2014 Municipality of Laurier Station\t\t\t\t\t Mme Marguerite Jobin.\t.P-379.\t\t\t\t100.40 \t\t\t\t\t Municipalité de Issoudun \u2014 Municipality of Issoudun\t\t\t\t\t Yvon Gallant.\t.P-28.\t8 3.61\t8 9.42 14.26\t$\t13.03 19.79 \t.P-40.\t6.63\t\t\t \t\t\t\t\t Municipalité de Villeroy \u2014 Municipality of Villeroy\t\t\t\t\t \t.639-21, R-18, 638-22, R-18.\t8 2.55\t\tt\t2.65 3.47 Roy & Raylde.\t.646-P-1.R-17.\t3.47\t\t\t \t\t\t\t\t Municipalité de St-Louis de Lotbinière \u2014 Municipality of St-Louis de Lotbinière Emilien Mailhot P-497, P-496 8 1.77 $ 1.77 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 957 Municipalité de St-Octave de Dosquet \u2014 Municipality of St-Octave de Dosquet\t\t\t\t Noms des propriétaire»\tNuméros du cadastre\tTaxes munie.\tTaxes scolaires\tTotal Names of owners\tCadastral numbers\tMunie, taxes\tSchool taxes\t \t\t$ 7.45\tS 29.45\t$ 36.90 Michel Bérubé.\t____ P-319.\t26.00\t142.56\t168.56 Max Clarfeld.\t____ P-363-1, P-354-1.\t40.70\t120.30\t161.00 \t\t\t\t Municipalité de St-Janvier de Joly \u2014 Municipality of St-Janvier de Joly Roland Bourgon.388-165, R-IV.Marcel Bourgon.388-P-152, R-IV.Denis Turgeon.388-259, 388-258, 388-257, R-IV.Ronald Beaudet.388-114.R-III.Ronald Beaudet.T-22, 388-P-133, It-III.41.60 40.95 164.40 27.30 196.00 24.00 41.60 64.95 164.40 27.30 196.00 Signé à Ste-Croix, Lotbinière, ce 8e jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44135-3-2-0 Marcel Lafleur.Signed at Ste-Croix, Lotbinière, this 8th day of January, 1972.Marcel Lafleur, 44135-3-2-0 Secretary-Treasurer.Municipalité scolaire de Ville d'Anjou Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, que : Les Commissaires de la Commission Scolaire de Ville d'Anjou par une résolution adoptée à l'assemblée tenue le septième jour du mois de décembre, mil neuf cent soixante-onze (1971), ont autorisé le soussigné, secrétaire-trésorier, conformément aux articles 416 et suivants de la Loi de l'Instruction Publique et aux articles 726 et suivants du Code Municipal, à procéder à la vente des immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues à la Commission Scolaire de Ville d'Anjou, avec intérêts et frais, et qu'en conséquence, lesdits immeubles seront vendus par encan public dans la salle du Conseil de la Commission Scolaire, 6311 avenue Merriam, à Ville d'Anjou, le NEUVIÈME j our du mois de MARS, 1972, à DIX heures de l'avant-midi, heure normale de l'est, à moins que lesdites taxes, les intérêts et les frais soient payés avant la vente.Ville d'Anjou Scbool Municipality Public notice is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer of the aforesaid municipality of the Province of Québec: The Commissioners of Ville d'Anjou School Board, by a resolution adopted at the meeting held on the seventh day of the month of December, one thousand nine hundred and seventy-one (1971), have authorized the undersigned, the Secretary-Treasurer, in conformity with section 416 and subsequent sections of the Education Act and article 726 and subsequent articles of the Municipal Code, to proceed with the sale of the immoveables described hereunder for non-payment of arrears of taxes due the Ville d'Anjou School Board, including interest and costs, and that consequently, the said immoveables will be sold by public auction, in the School Board Council Hall, 6311 Merriam Avenue, Ville d'Anjou, on the NINTH day of the month of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, Eastern Standard Time, unless the said taxes, interest and costs are paid before the sale.Vente d'immeuble pour non-paiement des taxes \u2014 Sale of immoveables for non-payment of taxes Immeubles sujets au droit de retrait de deux ans \u2014 Immoveables subject to a right of withdrawal of two years (Les lots ci-après décrits sont du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe, dans les limites de la ville d'Anjou \u2014 The lots hereafter described are of the official cadastre of the parish of Longue-Pointe, in the limits of the town of Anjou.) Folio\tNoms Names\tCadastre subd.Cadastre subd.\tTaxes scolaires School taxes\tIntérêts frais Interest costs\tTotal\tTaxes munie.Munie, taxes\tIntérêts Interest\tTotal\tGrand total Grand total 030-0704 030-0712\tMarchand.Pierre, 7451 Baldwin.\t423-195 P.\t$ 271.87\tS 34.84\tS 306.71\tS 432.66\t$ 25.45\t$ 458.01\t8 764.72 1.Un emplacement composé d'une partie du lot 423-195 1.An emplacement composed of a part of lot 423-195, this mesurant cettedite partie 15 pieds de largeur par 72 pieds de part measuring 15 feet in width by 72 feet in depth, containing 958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101' année, n° A \t\tCadastre\tTaxes\tIntérêts\t\tTaxes\t\t\tGrand \tNoms\tsubd.\tscolaires\tfrais\t\tmunie.\tIntérêts\t\ttotal Folio\t\t\t\t\tTotal\t\t\tTotal\t \tNames\tCadastre subd.\tSchool taxes\tInterest costs\t\tMunie, taxes\tInterest\t\tGrand total profondeur,, contenant une superficie de 1,080 pieds carrée mesure anglaise et plus ou moins, et bornée comme suit: en front à une autre partie dudit lot numéro 423-195, en arrière à une partie du lot numéro 423-219, du côté nord par une partie dudit lot 423-195, et du côté sud par une partie du lot numéro 423-196.Du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe dans les limites de la Ville d'Anjou.| 423-196P.J 1.Un emplacement composé d'une partie du lot 423-196 mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur, contenant une superficie de 2,160 pieds carrés mesure anglaise et plus ou moins, et bornée comme suit: en front à une autre partie dudit lot numéro 423-196 en arrière à une partie du lot numéro 423-219, du côté nord par une partie du lot numéro 123- L95, et du côté sud par une partie du lot numéro 197.Du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe dans les limites de la Ville d'Anjou.| 423-197 P.J 1.Un emplacement composé d'une partie du lot 423-197 mesurant cette dite partie 15 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur, contenant une superficie de 1,080 pieds carrés mesure anglaise et plus ou moins, et bornée comme suit: en front à une autre partie du lot numéro 423-197, en arrière à une partie du lot numéro 423-219, du côté nord par une partie du lot numéro 423-196, et du côté sud par une partie du lot numéro 423-198.Du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe dans les limites de la Ville d'Anjou.1,080 square feet, English measure, and more or less, bounded as follows: in front by another part of said lot number 423-195, in the rear by a part of lot number 423-219, on the north side by a part of said lot 423-195 and on the south side by a part of lot number 423-196.Of the official cadastre of the Parish of Longue-Pointe, in the limits of Ville d'Anjou.1.An emplacement composed of a part of lot 423-196, this part measuring 30 feet in width by 72 feet in depth, containing 2,160 square feet.English measure, and more or less, bounded as follows: in front by another part of said lot number 423-196, in the rear by a part of lot number 423-219, on the north side by a part of lot number 423-195, and on the south side by a part of lot number 197.Of the official cadastre of the parish of Longue-Pointe, in the limits of Ville d'Anjou.1.An emplacement composed of a part of lot 423-197, this said part measuring 15 feet in width by 72 feet in depth, containing 1.080 square feet, English measure, and more or less, bounded as follows: in front by another part of lot number 423-197, in the rear by a part of lot number 423-219, on the north side by a part of lot number 423-196, and on the south side by a part of lot number 423-198.Of the official cadastre of the Parish of Longue-Pointe, in the limits of Ville d'Anjou.295-0698 295-0694 419-307____ 419-308 P.S 22.74 Nadon, Monique Mlle 6580, 41e Avenue, Rose mont.1.Un emplacement composé d'une partie du lot 419-308 mesurant 15 pieds de largeur par 70 pieds de profondeur, contenant une superficie de 1,050 pieds carrés mesure anglaise et plus ou moins, et bornée comme suit: en front par une partie du lot numéro 419-278 (rue Levesque), en arrière par une partie du lot numéro 419-407, du côté nord par une partie du lot numéro 419-307 et du côté sud par une partie du lot numéro 419-309 et une autre partie du lot 419-308.Du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe dans les limites de la Ville d'Anjou.S 6.29.60 $ 210.43 $ 12.36 $ 222.79 252.39 040-0056 040-0076 040-0080 040-0084 040-0088 040-0092 040-0096 040-0100 1.An emplacement composed of a part of lot 419-308 measuring 15 feet in width by 70 feet in depth, containing 1,050 square feet, English measure, and more or less, bounded as follows: in front by a part of lot number 419-278 (Levesque Street), in the rear by a part of lot number 419-407, on the north side by a part of lot number 419-307 and on the south side by a part of lot number 419-309 and another part of lot 419-308.Of the official cadastre of the Parish of Longue-Pointe, in the limits of Ville d'Anjou.Asselin, Emile, 40 Elrawood, Outremont.Asselin, Emile 40 El m wood, Outre mon t.Asselin Emile, 40 El m wood, Outremont.Asselin, Emile 40 Elmwood, Outremont.Asselin, Emile 40 Elmwood, Outremont.Asselin, Emile 40 Elmwood, Outremont.Asselin, Emile 40 Elmwood, Outremont.Asselin, Emile, 40 Elmwood, Outremont.440-1289.\t1,919.28\t320.97\t2,240.25\t4,211.67\t247.52\t4,459.19\t6,699.44 440-1282-1.\t128.44\t21.28\t149.72\t264.36\t15.58\t279.94\t429.66 440-1282-2.\t169.06\t28.03\t197.09\t380.84\t22.38\t403.22\t600.31 440-1282-3.\t169.29\t28.08\t197.37\t381.38\t22.38\t403.76\t601.13 440-1282-4.\t172.74\t28.66\t201.40\t383.90\t22.57\t406.47\t607.87 440-1282-5\t198.13\t32.80\t230.93\t457.19\t26.86\t484.05\t714.98 440-1282-6\t173.23\t28.78\t202.01\t385.22\t22.63\t407.86\t609.86 440-1282-7\t173.39\t28.85\t202.24\t386.44\t22.64\t408.08\t610.32 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 959 \t\tCadastre\tTaxes\tIntérêts\t\tTaxes\t\t\tGrand \tNoms\tsubd.\tscolaires\tfrais\t\tmunie.\tIntérêts\t\ttotal Folio\t\t\t\t\tTotal\t\t\tTotal\t \tNames\tCadastre\tSchool\tInterest\t\tMunie.\tInterest\t\tGrand \t\tsubd.\ttaxes\tcosts\t\ttaxes\t\t\ttotal 040-0104\tAsselin.Emile,\t440-1282-8\t$ 176.69\tS 29.36\t$ 206.05\t$ 387.63\tS 22.80\t$ 410.43\tî 616.48 \t40 Elmwood,\t\t\t\t\t\t\t\t \tOutremont.\t\t\t\t\t\t\t\t 040-0108\tAsselin, Emile,\t440-1282-9\t176.76\t29.38\t206.14\t387.77\t22.80\t410.57\t616.71 \t40 Elmwood,\t\t\t\t\t\t\t\t \tOutremont.\t\t\t\t\t\t\t\t 040-0112\tAsselin, Emile,\t440-1282-10\t176.76\t29.38\t206.14\t387.79\t22.80\t410.69\t616.73 \t40 Elmwood,\t\t\t\t\t\t\t\t \tOutremont.\t\t\t\t\t\t\t\t 288-0830\tAsselin, Emile,\t440-1290\t6,017.38\t994.04\t7.011.42\t15,554.81\t835.62\t16,390.33\t23,401.75 \t40 Elmwood,\t\t\t\t\t\t\t\t \tOutremont.\t\t\t\t\t\t\t\t 440-2132\tAsselin, Emile,\t440-1378\t2,111.38\t333.74\t2,445.12\t6,055.73\t355.82\t6,411.55\t8,856.67 440-2136\t40 Elmwood,\t\t\t\t\t\t\t\t 440-2140\tOutremont.\t\t\t\t\t\t\t\t 440-2144\t\t\t\t\t\t\t\t\t 440-2192\t\t\t\t\t\t\t\t\t 440-2196\t\t\t\t\t\t\t\t\t 440-2200\t\t\t\t\t\t\t\t\t 440-2204\t\t\t\t\t\t\t\t\t 440-1480\t\t\t\t\t\t\t\t\t 515-0164\tBartoloméo, Romano,\t418-78\t103.96\t17.63\t121.49\t206.46\t12.12\t218.58\t340.07 \t2870 Paradis, -\t418-81\t\t\t\t\t\t\t \tMontréal.\t\t\t\t\t\t\t\t 233-0154\tBeauregard, Maurice,\t440-1265-6\t168.22\t29.28\t197.50\t364.10\t21.40\t385.60\t583.00 \t89, boul.Dusseault.\t440-1266-16\t\t\t\t\t\t\t \tLaval.\t\t\t\t\t\t\t\t 233-0158\tBeauregard, Maurice,\t440-1265-7\t171.80\t28.89\t200.69\t419.32\t24.63\t443.95\t644.64 \t89, boul.Dusseault,\t440-1266-17\t\t\t\t\t\t\t \tLaval.\t\t\t\t\t\t\t\t 233-0162\tBeauregard, Maurice,\t440-1266-18\t171.80\t28.89\t200.69\t419.32\t24.63\t443.95\t644.64 \t89, boul.Dusseault,\t\t\t\t\t\t\t\t \tLaval.\t\t\t\t\t\t\t\t 600-0080\tBouchard, Padoue,\t424-643\t1,118.94\t210.93\t1,329.87\t650.27\t38.20\t688.47\t2,018.34 \t8399 boul.Wilirid-\t\t\t\t\t\t\t\t \tPelletier.Ville\t\t\t\t\t\t\t\t \td'Anjou.\t\t\t\t\t\t\t\t 280-0180\tChalifoux, Marcel,\t429-1691\t3,530.78\t637.60\t4,168.38\t1,683.10\t98.90\t1,782.00\t5,950.38 \t1570 Prieur Est,\t\t\t\t\t\t\t\t \tMontréal.\t\t\t\t\t\t\t\t 280-0184\tChalifoux, Marcel,\t429-1692\t3,492.34\t627.77\t4,120.11\t1.679.06\t98.66\t1,777.72\t6,897.83 \t1570 Prieur Est,\t\t\t\t\t\t\t\t \tMontréal.\t\t\t\t\t\t\t\t 280-0188\tChalifoux, Marcel,\t429-1693\t3,300.94\t598.78\t3,899.72\t1,666.26\t92.02\t1,658.28\t5,558.00 \t1570 Prieur Est,\t\t\t\t\t\t\t\t \tMontréal.\t\t\t\t\t\t\t\t 280-0192\tChalifoux, Marcel,\t429-1694\t2,079.85\t368.88\t2,448.73\t2,017.83\t122.13\t2,139.96\t4,588.69 \t1570 Prieur Est,\t430-434\t\t\t\t\t\t\t \tMontréal.\t\t\t\t\t\t\t\t 515-0128\tBaker, Stanley,\t418-58\t1,071.60\t202.13\t1,273.63\t665.54\t33.27\t598.81\t1,872.44 515-0124\t1449, St-Alexandre,\t418-61\t\t\t\t\t\t\t \tChambre 1001,\t\t\t\t\t\t\t\t \tMontréal.\t\t\t\t\t\t\t\t 468-0022\tDurand, Hervé,\t467-34\t1,217.45\t221.26\t1,438.71\t779.91\t45.84\t825.76\t2,264.46 \t8670 D'Allonnes,\t468-39\t\t\t\t\t\t\t \tVille d'Anjou.\t\t\t\t\t\t\t\t 204-0012\tEntreprise Octogonal\t438-42\t10.00\t3.97\t13.97\t1.720.14\t84.12\t1,804.26\t1,818.23 \tInc., 7522 boul.\t\t\t\t\t\t\t\t \tOctogonal,\t\t\t\t\t\t\t\t \tSt-Michel, Mtl.\t\t\t\t\t\t\t\t 204-0014\tEntreprise Octogonal\t438-44\t10.00\t3.97\t13.97\t1,720.14\t84.12\t1,804.26\t1,818.23 \tInc., 7522 boul.,\t\t\t\t\t\t\t\t \tOctogonal,\t\t\t\t\t\t\t\t \tSt-Michel, Mtl.\t\t\t\t\t\t\t\t 575-0144\tForest, Henri,\t473-103\t1,326.79\t266.40\t1,693.19\t685.78\t40.31\t726.09\t2,319.28 \t461 Tiffin No 1,\t475-70\t\t\t\t\t\t\t \tSt-Lambert.\t\t\t\t\t\t\t\t 365-0008\tGomory, John ivan,\t424-650\t1,216.00\t231.60\t1,447.60\t628.61\t36.96\t665.57\t2,113.17 \t8388 Peterborough,\t\t\t\t\t\t\t\t \tVille d'Anjou.\t\t\t\t\t\t\t\t 415-0212\tHorvath, Alexander,\t415-20\t33.20\t8.03\t41.23\t14.40\t0.60\t15.00\t56.23 960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Folio 415-0571 417-0151 417-0263 417-0264 417-0276 417-0277 417-0309 417-0310 417-0328 417-0329 417-0330 417-0436 417-0437 417-0438 417-0439 417-0444 417-0445 Noms Names 26, Anselme, Lavigne, Dollard Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26 Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, DollardB Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Horvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.Cadastre subd.Cadastre subd.\tTaxes scolaires School taxes\tIntérêts frais Interest costs\tTotal\tTaxes munie.Munie, taxes\tIntérêts Interest\tTotal\tGrand total Grand total 415-379\tS 33.20\tt 8.03\tS 41.23\tS 14.40\tS 0.60\tS 15.00\tS 66.23 417-138\t24.87\t6.37\t31.24\t14.40\t0.60\t15.00\t46.24 417-250\t24.87\t6.37\t31.24\t14.40\t0.60\t15.00\t46.24 417-251\t24.87\t6.37\t31.24\t14.40\t0.60\t15.00\t46.24 417-263\t24.87\t6.37\t31.24\t14.40\t0.60\t16.00\t46.24 417-264\t24.87\t6.37\t31.24\t14.40\t6.60\t16.00\t46.24 417-296\t24.87\t6.37\t31.24\t14.40\t0.60\t15.00\t46.24 417-297\t24.87\t6.37\t31.24\t14.40\t0.60\t15.00\t46.24 417-315\t24.44\t6.31\t30.75\t12.80\t0.55\t13.35\tt 44.10 417-316\t24.44\t6.31\t30.75\t12.80\t0.55\t13.35\t44.10 417-317\t24.87\t6.37\t31.24\t14.40\t0.60\t15.00\t46.24 417-423\t49.71\t10.19\t59.90\t14.40\t0.60\t15.00\t74.90 417-424\t36.40\t8.44\t43.84\t12.80\t0.66\t13.35\t67.19 417-426\t36.40\t8.44\t43.84\t12.80\t0.65\t13.36\t67.19 417-426\t35.40\t8.44\t43.84\t12.80\t0.55\t13.35\t67.19 417-431\t31.40\t6.72\t38.12\t12.80\t0.65\t13.35\t61.47 417-432\t31.40\t6.72\t38.12\t12.80\t0.66\t13.35\t61.47 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.4 961 \t\tCadastre\tTaxes\tIntérêts\t\tTaxes\t\t\tGrand \tNoma\tsubd.\tscolaires\tfrais\t\tmunie.\tIntérêts\t\ttotal Folio\t\t\t\t\tTotal\t\t\tTotal\tGrand total \tNames\tCadastre subd.\tSchool taxes\tInterest costs\t\tMunie, taxes\tInterest\t\t 417-0446\tHorvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.\t417-433\t* 33.20\tS 7.03\tS 40.23\tS 14.40\t* 0.60\t$ 15.00\t$ 55.23 417-0477\tHorvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.\t417-464\t35.40\t8.44\t43.84\t12.80\t0.66\t13.36\t67.19 417-0478\tHorvath, Alexander, 26, Anselme, Lavigne, Dollards Des Ormeaux.\t417-465\t37.20\t8.75\t45.95\t14.40\t0.60\t16.00\t60.95 025-0832\tJoyal, Yvan, 7356 AzQda, Ville d'Anjou.\t423-280 P 423-281 P\t474.83\t95.61\t670.44\t303.12\t17.80\t320.92\t891.36 1.Un emplacement composé d'une partie du lot 423-280 mesurant 20 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur, contenant une superficie de 1,440 pieds carrés mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit: en front par une partie du lot numéro 423-255 (avenue Azilda), en arrière par une partie du lot numéro 420^554, du côté nord par une partie du lot numéro 423-280 et du côté sud par une partie du lot numéro 423-281.Du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe dans les limites de la Ville d'Anjou.1.Un emplacement composé d'une partie du lot 423-281 mesurant 30 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur contenant une superficie de 2,160 pieds carrés mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit: en front par une partie du lot numéro 423-255 (avenue Azilda), en arrière par une partie des lots numéros 420-554 et 420-574, du côté nord par une partie du lot numéro 423-280 et du côté sud par une partie du lot numéro 423-282.Du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe dans les limites de la Ville d'Anjou.186-0012 200-0106 186-0028 295-0782 186-0024 233-0118 340-0268 395-0608 395-0612 615-0368 516-0364 030-2188 Lessard, Marcc, 1017, 1ère Avenue, Pte-aux-Trembles.Mannella, Dominique, 6821 De La Loire, Ville d'Anj.Morin, Jacques Daniel, 8509 Du Chardonnet, Ville , i ' A i.j.-11.Perodin, Raoul, 7708 Levesque, Ville d'Anjou.Pratte, Réal, 12279 Gratton, Pte-aux-Trembles.Saucier, Charles, 6171 Du Bocage, Ville d'Anjou.St-André, Jean-Paul, 8283 Montrichard, Ville d'Anjou.Sudomlak, Osyp, 3195 Lacordaire.Sudomlak, Osyp, 3195 Lacordaire.Thibault, Raymond, 7331 Rondeau, Ville d'Anjou.Thibodeau, Conrad, 473-172 475-231 424-620 473-176 775-235 419-401 473-175 475-234 440-1277-19 431-315 420-334 420-335 418-164 418-165 423-673 1 P 423-674 1 P 861.11 1,322.25 748.06 1,046.12 889.57 1,248.38 1.769.76 95.95 95.95 177.62 643.70 1.An emplacement composed of part of lot 423-280 measuring 20 feet in width by 72 feet in depth, containing 1,440 square feet, English measure, and more or less, bounded as follows: in front by a part of lot number 423-255 (Azilda Avenue), in the rear by a part of lot number 420-554, on the north side by a part of lot number 423-280 and on the south side by a part of lot number 423-281.Of the official cadastre of the Parish of Longue-Pointe, in the limits of Ville d'Anjou.1.An emplacement composed of a part of lot 423-281 measuring 30 feet in width by 72 feet in depth, containing 2,160 square feet, English measure, and more or less, bounded as follows: in front by a part of lot number 423-255 (Azilda Avenue), in the rear by a part of lots numbers 420-554 and 420-574, on the north side by a part of lot number 423-280 and on the south side by a part of lot number 423-282.Of the official cadastre of the Parish of Longue-Pointe, in the limits of Ville d'Anjou.146.19 246.62 117.31 189.21 155.85 225.06 213.62 16.47 16.47 22.62 5740 Baldwin, Ville d'Anjou.1.Un emplacement composé d'une partie du lot 423-673rl mesurant 30 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur, contenant une superficie de 2,100 pieds carrés mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit: en front par une 103.00 1,007.30 1,568.87 865.37 1,235.33 1,045.42 1,473.44 1,983.38 112.42 112.42 200.04 746.70 685.51 768.95 787.96 487.33 662.40 750.37 738.50 267.65 267.65 406.73 406.98 40.31 44.60 46.31 28.62 38.90 44.08 43.43 15.76 16.76 23.92 23.92 725.82 803.65 824.27 515.95 701.30 794.45 781.93 283.41 283.41 430.65 430.90 1,733.12 2,372.42 1.699.64 1,751.28 1,746.72 2,267.89 2,765.31 395.83 395.83 630.69 1,177.60 1.An emplacement composed of a part of lot 423-673-1 measuring 30 feet in width by 72 feet in depth, containing 2,160 square feet, English measure, and more or less, bounded as follows: in front by a part of lot number 423-676 (Baldwin 962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 39 janvier 1973, 104' année, n° 4 \t\tCadastre\tTaxes\tIntérêts\t\tTaxes\t\t\tGrand \tNoms\tsubd.\tscolaires\tfrais\t\tmunie.\tIntérêts\tTotal\ttotal Folio\t\t\t\t\tTotal\t\t\t\t \tNames\tCadastre\tSchool\tInterest\t\tMunie.\tInterest\t\tGrand total \t\tsubd.\ttaxes\tcosts\t\ttaxes\t\t\t partie du lot numéro 423-676 (avenue Baldwin) en arrière par une partie des lots numéros 424-774 et 424-773, du côté nord par une partie du lot numéro 423-672 et du côté sud par une partie du lot numéro 423-674,-1.Du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe dans les limites de la Ville d'Anjou.1.Un emplacement composé d'une partie du lot 423-674-1 mesurant 4 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur contenant une superficie de 288 pieds carrés mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit: en front par une partie du lot numéro 423-676 (avenue Baldwin) en arrière par une partie des lots numéros 424-774 et 424-775, du côté nord par une partie du lot numéro 423-673-1 et du côté sud par une partie du lot numéro 423-674-2.Du cadastre officiel de la paroisse de Longue-l'ointe dans les limites de la Ville d'Anjou.200-0242 370-0060 670-0994 610-0994 417-0497 570-0052 416-0011 320-1476 Verreault, Emile, 7201 De La Loire, Ville d'Anjou.Verreault, Emile, 7201 De La Loire, Ville d'Anjou.Verreault, Emile, 7201 De La Loire, Ville d'Anjou.Viau, W R Mme, a/s Mercier, Pierre, Mme, 5791 Deom, Mtl.Villa, Antonio, 8442 Pl.Verdelle, Ville d'Anjou.M.et Mme Di Lillo, Antonio, 6356 Maurice Duplessis, Appt.2, Montréal-Nord.Avenue), in the rear by a part of lots numbers 424-774 and 424-773, on the north side by a part of lot number 423-672 and on the south side by a part of lot number 423-674-1.Of the official cadastre of the Parish of Longue-Pointe, in the limits of Ville d'Anjou.1.An emplacement composed of a part of lot 423-674-1 measuring 4 feet in width by 72 feet in depth, containing 288 square feet, English measure, and more or less, bounded as follows: in front by a part of lot number 423-676 (Baldwin Avenue), in the rear by a part of lots numbers 424-774 and 424-775.on the north side by a part of lot number 423-673-1 and on the south side by a part of lot number 423-674-2.OI the official cadastre of the Parish of Longue-Pointe, in the limits of Ville d'Anjou.426-333\t$1,815.01\t$385.80\t$2,200.81\t$ 839.06\t$ 49.31\t$ 888.36\t$ 3,089.17 424-1017\t1,531.96\t327.53\t1,859.49\t612.93\t36.03\t648.96\t2,508.45 424-896-26\t906.11\t144.79\t1,049.90\t623.97\t36.67\t660.64\t1,710.54 417-484\t49.71\t11.19\t60.90\t7.45\t0.42\t7.87\t68.77 424-569\t992.66\t114.13\t1,106.69\t639.24\t37.56\t676.SO\t1,783.49 416-490 P\t1,067.16\t243.61\t1,300.67\t404.16\t23.74\t427.90\t1,728.67 1.Un emplacement de forme rectangulaire ayant front sur le boulevard Métropolitain, à Ville d'Anjou, Province de Québec, connu et désigné comme étant une partie du lot de subdivision numéro quatre cent quatre-vingt-dix du lot originaire numéro quatre cent seize (416-P.490) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de la Longue Pointe, mesurant soixante- i i'.-i^.i; ; pieds et quatre centièmes de pied (79.04') de largeur dans ses lignes nord-ouest et sud-est par sept cent quarante-sept pieds et cinquante-quatre centièmes de pied (747.54') de profondeur dans ses lignes nord-est et sud-ouest, mesures anglaises et plus ou moins, et bornée en front au nord-ouest par le lot 416-490 dudit cadastre (ligne homologuée du boulevard Métropolitain), à 1 barrière au sud-est et d'un côté au sud-ouest par le résidu dudit lot 416-490 et de l'autre côté au nord-est par partie du lot numéro 416-488 dudit cadastre.Du cadastre'officiel de la paroisse de Longue-Pointe dans les limites de la Ville d'Anjou.Taxes scolaires: $47,410.97; intérêts: $8,380.62.Total: $55,791.59.Taxes municipales: $55,312.11; intérêts: $3,136.76.Total: $58,448.87.Grand total: $114,240.46.1.An emplacement of a rectangular configuration fronting on Metropolitan Boulevard, Ville d'Anjou, Province of Québec, known and described as being a part of subdivision lot number four hundred and ninety of original lot number four hundred and sixteen (416-P.490) in the official plan and book of reference of the Parish of Longue Pointe, measuring seventy-nine and four hundredths feet (79.04') in width on its northwest and southeast lines by seven hundred and forty-seven and fifty-four hundredths feet (747.54') in depth on its northeast and southwest lines, English measure and more or less, bounded in front on the northwest by lot 416-490 of the said cadastre (confirmed line of Metropolitan Boulevard), in the rear on the southeast and on one side on the southwest by the remainder of said lot 416-490 and on the other side on the northeast by part of lot number 416-488 of the said cadastre.Of the official cadastre of the Parish of Longue-Pointe, in the limits of Ville d'Anjou.School taxes: $47,410.97; interests: $8,380.62.Total: $55,791.59.Municipal taxes: $55,312.11; interests: $3,136.76.Total: $58,448.87.Grand Total: $114,240.46.(Cette liste d'immeubles est affichée au bureau de la Commission Scolaire, au 6311 avenue Merriam, et au bureau de l'Hôtel de Ville de la Ville d'Anjou, au 7701 Montée St-I.éonard).Us seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances s'il y a lieu, sujets à tous les droits acquis de la Ville d'Anjou et à toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes pouvant les affecter.(This list of immoveables is posted in the School Board Office, 6311 Mcrriam Avenue, and at the Town Hall Office, Ville d'Anjou, 7701 Montée St-Lconard.) They will be sold with buildings erected thereon, circumstances and dependencies if required, subject to all the rights purchased from Ville d'Anjou and all active or passive, apparent or unapparent servitudes affecting them. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 963 Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.La vente sera en outre sujette aux dispositions de la Loi de l'Instruction Publique et du Code Municipal.Donné à Ville d'Anjou, ce 14e jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44142-3-2-0 Pierre Racine, ca.Municipalité du comté de Rouville Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Rita Rondeau, secrétaire-trésorier de la Corporation municipale du comté de Rouville,.que les immeubles ci-après énumérés comprenant les bâtisses dessus construites, s'il en existe alors, seront vendus à l'enchère publique au Chef-lieu du comté de Rouville, à Marie-ville au 1601 rue Edmond Guillet, dans la salle des sessions dudit conseil de comté, JEUDI le NEUVIÈME jour de MARS 1972 à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes et autres redevances dues aux municipalités mentionnées ci-dessous, plus les frais subséquemment encourus, à moins que ces taxes, redevances et frais ne soient payés avant la vente : The awarded price of each of these immoveables will be payable immediately.The sale is subject to the provisions of the Education Act and the Municipal Code.Given at Ville d'Anjou, this 14th day of January, 1972.Pierre Racine, ca., 44142-3-2 Secretary-Treasurer.Municipality of the County of Rouville Public notice is hereby given by the undersigned, Rita Rondeau, Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of the County of Rouville, that the immoveables hereinafter enumerated, including the buildings erected thereon, if any, will be sold by public auction at the County Seat of the County of Rouville, in Marieville, 1601 Edmond Guillet Street, in the Council Hall of the Countv, on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon for the payment of taxes and other dues owed the municipalities hereunder mentioned, plus the subsequent costs incurred, unless these taxes, dues and costs are paid before the sale : Notre-Dame de Bonsecours \u2014 Notre-Dame of Bonsecours Taxes Taxes Int.Nom du propriétaire Numéro de cadastre munie.scol.et frais Name of the proprietor Number of the cadastre Munie.School Int.taxes taxes and cost Cotolesse, Primo.12-27.Cotolesse, Primo.12-28.Businvest Inc.P.12.Emplacement d'une superficie de 17.9 arp.Businvest Inc.P.14.Emplacement d'une superficie de 11.5 arp.Savard, Dina (Gagnon).55-3 Surprenant, Pierre.89.D'une superficie de 83 arp.Borné par le chemin de la Savane; par la propriété de René Besse,tte et par la propriété de André Darche.15.16 14.62 49.38 An emplacement containing 17.9 arpents.158.59 An emplacement containing 11.5 arpents.2.19 2.14 6.44 15.81 .42.09 4.76 .S 88.00 338.58 41.23 Containing 83 arpents.Bounded by the Savane Road, by the property of René Bessette and by the property of André Darche.Du cadastre officiel du Village de Richelieu \u2014 Official cadastre of the Village of Richelieu Tétreault, Réjean.P.54.$ 67.72 S 7.18 D'une superficie de 22,000 p.c.borné par le boul.Swail; par Containing 22,000 sq.ft.Bounded by Swail Boulevard, by la propriété de Marcel Roy; par la propriété de B.P.Canada the property of Marcel Roy, by the property of B.P.Canada Ltée; par la propriété de Robert Catien ; et la 5e rue.Ltée, by the property of Robert Gatien and 5th Street.La Commission scolaire de St-Césaire \u2014 St.Césaire School Board Du cadastre de la Paroisse de St-Césaire \u2014 Cadastre of the Parish of St.Césaire Adams, Yves.182-2.Adams, Marcel.182-1.Gosselin, Marcel.P.346 Superficie d'environ 3,200 p.c.Décrit au No 91897 enregistré à Rouville et à distraire partie vendue No 94773 enregistré à Rouville.S 15.60 S .96 .12.87 .82 .1.39 .11 Containing about 3,200 sq.ft.Described in No.91897 registered at Rouville, save and to withdraw the part sold No.94773, registered at Roijyille. 964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10À' année, n\" L Du cadastre du Village de St-Césaire \u2014 Cadastre of the Village of St.Césaire \t\tTaxea\tTaxes\tInt.Nom du propriétaire\tNuméro de cadastre\tmunie.\tscol.\tet frais Name of the proprietor\tNumber of the cadastre\tMunie.\tSchool\tInt.\t\ttaxes\ttaxes\tand cost \t.101.\t\tS 288.32\ti 7.64 La Commission scolaire de Mane ville \u2014 Marieville School Board Du cadastre de Marieville \u2014 Cadastre of Marieville Dalpé, Louise MUe-Miss.(H ina.) 147-2-1.t 367.49 * 63.00 D'une superfioie de 4,715 p.c.situé rue Chambly.Containing 4,715 sq.ft., situated on Chambly Street.Messier, Maurice.147-P.13.467.10 69.63 D'une superficie de 10,735 p.c.situé rue Ouellette.Containing 10,736 sq.ft., situated on Ouellette Street.Messier, Maurice.196-2.336.52 47.69 D'une superficie de 4,743 p.c.situé rue Chambly.Containing 4,743 sq.ft., situated on Chambly Street.Du cadastre de Ste-Marie de Monnoir \u2014 Cadastre of St.Marie de Monnoir Marier, Claire MUe-Miss.166-4-P.4, 156-6-4.8 25.24 $ 3.81 D'une superficie de 5,000 p.c.situé rue St-Césaire.Containing 5,000 sq.ft., situated on St.Césaire Street.Les Commissaires d'écoles de St-Hilaire - Otterburn Park \u2014 The St.Hilaire School Commissioners - Otterburn Park Du cadastre de la Paroisse de St-Hilaire \u2014 Cadastre of the Parish of St.Hilaire Dupuis, René.146-28.S 393.01 $ 37.87 Dupuis, René.146-29.19.22 Dupuis, René.146-30.19.22 Dupuis.René.146-31.19.22 Mont St-Hilaire Brault, Mme-Mrs.Réjeanne (Robert).261-116.Laliberté, Marc.261-71.Vallée & Lamoureux.281-31.Robitaille suce, de-est.of Mme Françoise (Groulx).244-22.Robitaille suco.-est.Mme Françoise.244-23.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.246-19, 244-17, 244-19.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.243-18.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.2~4J>22.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.246-51.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.246-20.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.244-20.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.244-21.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.244-24.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.244-25.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.244-26.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.244-27.Robitaille succ.-est.Mine Françoise.244-28.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.244-29.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.246-11 .Robitaille succ.-est.Mme Françoise.246-12.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.246-13.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.246-14 et 244-10.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.24,6-15 et 244-11.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.246-16 et 244-15.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.246-17 et 244-13.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.246-23.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.244-14.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.244-15.Robitaille succ.-est.Mme Françoise.244-9.$ 612.\t27 $\t49.12 14.\t39\t5.64 16.\t95\t6.05 14.\t68\t1.86 16\t31\t1.63 is.\t13\t1.70 15.\t70\t1.66 19.\t11\t1.80 20\t03\t1.89 17.\t31\t1.59 15\t49\t1.44 12\t84\t1.17 14\t07\t1.36 14\t67\t1.36 17,\t67\t1.75 24\t24\t2.30 18.\t13\t1.64 10\t39\t1.62 M\t03\t1.40 14\t49\t1.44 M\t21\t1.33 13\tS\\\t1.21 15\t86\t1.66 15\t49\t1.44 14\t68\t1.46 26\t94\t2.42 1-1\t68\t1.36 16\t76\t1.56 19\t86\t1.86 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101,, No.L 965 St-Michel de Rougemont Du cadastre de St-Jean Baptiste \u2014 Cadastre of St.Jean Baptiste Nom du propriétaire Name of the proprietor Numéro de cadastre Number of the cadastre Taxes munie.Munie, taxes Taxe3 scol.School taxes Int._ et frais Int.and cost Proulx, David.P.487.D'une superficie de 100' x 100' situé rang de la Montagne.S .86 $ 4.72 S .86 Containing 100' x 100'.situated on Montagne Range.Du cadastre de la Paroisse St-Damase annexé à St-Michel de Rougemont Cadastre of the Parish of St.Damase annexed to St.Michel de Rougement Inconnu-Unknown.400.Superficie de 3 arp.x 5 arp.situé rang Grande Caroline, ancien propriétaire, Adélard Ménard.S 6.67 S 17.73 « 4.82 Measuring 3 arpents x 6 arpents, situated on Grande Caroline Range, former property of Adélard Ménard.Paroisse de L'Ange-Gardien \u2014 Parish of Ange-Gardien Vermette (Deslauriers) Mme Litha.P.191.S 25.12 S 133.98 8 16.60 Superficie IA arp.rang St-Georges, tel que décrit acte No _ Containing \\}4 arpents.St.Georges Range as described 103474 enregistré à Rouville.in deed No.103474, registered in Rouville.St-Mathias Alpenha-us Restaurant Inc.P.218.Superficie d'environ 105 arp.A distraire partie vendue à Sa Majesté La Reine selon acte No 105990 enregistré à Rouville.Dalpé, Réal.28-258.Dalpé, Réal.28-7____ Robert, Henri succ.-est.38-19.Laroche, Ernest succ.-est.P.57.Terrain mesurant 50 pi.de largeur tant en front qu'à la profondeur par une profondeur de 75 pi.Borné à l'ouest par la rivière Richelieu, au sud par Joseph A.Archambault ou représentant, à l'est et au nord par d'autres parties du lot 57.Malo.Guy.28-107.Morin, Paul-René.28-10.Parent (Larithier) Madeleine.94-1 Picard, Armand.28-222.Raymond, Laurent.96-3.Ricard, Roger.38-3- St-Laurent, Jacques.25-118.Senecal, Jean-Marc.64.Théoret, Raymond.P.16.Lot mesurant environ 165 pi.de largeur en front par toute la profondeur entre le chemin public et la rivière Richelieu; à distraire environ 125 pi.partie expropriée par le ministre de la Voirie selon acte 106683.Borné; N.O.par partie du lot 16 appartenant à R.Théoret, N.E.par partie du lot 16 appartenant à Dame Eva Blanchette, S.E.par la route actuelle.S 124.15 $ 16.33 Containing about 105 arpents.Save and to withdraw the part sold to Her Majesty the Queen according to deed No.105990, registered in Rouville.S 2.34 2.34 3.22 9.72 1.82 .93 2.88 13.37 46.85 A tract of land measuring 50 feet in width both in front and in depth by a depth of 75 feet.Bounded on the west by the Richelieu River, on the south by Joseph A.Archambault or representative, on the east and north by other parts of lot 57.2.34 9.72 71.65 189.68 9.72 77.36 80.46 12.16 447.80 110.67 2.03 \u20229.76 24.63 2.95 10.49 10.87 2.33 56.79 14.64 A lot measuring about 165 feet in width in front by all the depth between the public road and the Richelieu River, save and to withdraw about 125 feet from the part expropriated by the Department of Roads according to deed 106683.Bounded on the northwest by part of lot 16 belonging to R.Théoret, on the northeast by part of lot 16 belonging to Mrs.Eva Blanchette, on the southeast by the present highway.12.26 74.02 Thibault, Lucien.28-117.18.10 75.20 Tubman, John W.110-1, 110-P.2, 112-P.2.561.54 Lot 110-P.2 étant résidu du lot 110-2 dont partie vendue Lot 110-Pt.2, being the remainder of lot 110-2, a part of selon acte No 79423.which was sold according to deed No.79423.Lot 112-P.2 étant résidu du lot 112-2 dont partie vendue Lot 112-Pl.2.being the remainder of lot 112-2, a part of selon acte No 79423.which was sold according to deed No.79423. 966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Taxes Taxes Int.Nom du propriétaire Numéro de cadastre munie.scol.et frais Name of the proprietor Number of the cadastre Munie.School Int.taxes taxes and cost Normand, Pierre.183-2 .Société de Culture des Terres noires Ltée.P.175.Lopin de terre faisant partie du lot P.175, borné vers le nord par le chemin, vers l'est par la ligne limitative de la paroisse St-Mathias et vers le sud O.par partie du lot 174 de St-Mathias.Société de Culture des Terres noires Ltée.176.Société de Culture des Terres noires Ltée.177.Société de Culture des Terres noires Ltée.178.Société de Culture des Terres noires Ltée.P.179.Distraire l'extrême partie sud-est dudit lot mesurant 1141.71 pi.dans sa ligne N.E.1,271.4 pi.dan3 ligno S.O., 602.50 pi.ligne sud-est et 586.4 pi.dans ligne N.O.Borné N.E.par partie lot 180, S.O.par lot 178, N.O.par résidu du lot 179 et S.E.par lot 371 de Ste-Marie de Monnoir.$ 18.35 S 2.07 .45 $ .03 .86 A tract of land being part of lot Pt.175, bounded on the north by the road, on the east by tbe boundary line of the Parish of St.Mathias and on the southwest by part of lot 174 of St.Mathias.14.75 .88 1.24 .13.65 .82 1.17 .14.43 .86 1.22 .12.48 .75 1.09 Save and to withdraw, the extreme southeast part of the said lot measuring 1141.71 feet on its northeast line.1.274.4 feet, on the southwest line, 602.59 feet on the southeast line and 586.4 feet on the northwest line.Bounded on the northeast by part of lot 180, on the southwest by lot 178, on the northwest by the remainder of lot 179 and on the southeast by lot 371 of St.Marie de Monnoir.Société de Culture des Terres noires Ltée.P.180.À déduire l'extrême partie S.E.du lot 180 mesurant 1,055.96 pi, ligne N.E., 1,141.71 pi.dans ligne S.O., 389.41 pi.ligne S.E.et 378.97 pi.ligne N.O.Borné au N.E.par lot 181, S.O.par lot 179, N.O.par lot 371.10.73 .64 .97 Save and to withdraw, the extreme southeast part of lot 180 measuring 1,055.96 feet on its northeast line, 1,141-71 feet on the southwest line, 389.41 feet on the southeast line and 378.97 feet on the northwest line.Bounded on the northeast by lot 181, southwest by lot 179, northwest by lot 371.Société de Culture des Terres Noires Ltée.196.Société de Culture des Terres noires Ltée.219.Société de Culture des Terres noires Ltée.172, 173.Société de Culture des Terres noires Ltée.197, P.198 A distraire du lot 198 un morceau de terre de 48,650 p.c.de superficie vendu à L.W.Ross, enregistré No 92917 et partie du lot 198 vendue à Louis Rousseau par Gilbert Le Poisson, enregistré No 72740.3.90 .23 .61 .2.60 .16 .42 .68 .04 .29 .32.73 1.96 2.45 Save and to withdraw from lot 198, a tract of land of 48,650 sq.ft.sold to L.W.Ross, registered under No.92917 and part of lot 198 sold to Louis Rousseau by Gilbert Le Poisson, registered under No.72740.Société de Culture des Terres noires Ltée.201.8.45 .60 .82 Du cadastre de Ste-Marie de Monnoir \u2014 Cadastre of St.Marie de Monnoir Société de Culture des Terres noires Ltée.376.Société de Culture des Terres noires Ltée.P.374 .A distraire partie de ce lot mesurant environ 3 arp.en superficie vendue à Philippe Martel enregistré au No 77060 situé à l'extrémité sud-est du lot.$ 4.03 $ .24 $ .62 .23.82 1.42 1.86 Save and to withdraw, part of this lot containing about 3 arpents sold to Philippe Martel, registered under No.77060, situated at the southeastern extremity of the lot.Société de Culture des Terres noires Ltée.369.Société de Culture de3 Terres noires Ltée.365.Société de Culture des Terres noires Ltée.364.Société de Culture des Terres noires Ltée.371.Société de Culture des Terres noires Ltée.363, P.362 A distraire du lot 362 partie vendue à Adrien Touchette enregistré No 43572.Droit de passage de 15 pi.de largeur en faveur du lot 371 de St-Jean Baptiste acte enregistré No 25264.18.95 49.82 11.28 248.85 9.26 1.13 2.98 .67 14.88 .55 1.52 3.61 1.01 17.04 .87 Save and to withdraw from lot 362, the part sold to Adrien Touchette, registered under No.43572.A right of way of 15 feet in width in favor of lot 371 of St.Jean Baptiste, deed registered under No.25264.8ociété de Culture des Terres noires Ltée.372.76.92 4.53 6.37 Given at Marieville, this 5th day of January, 1972.Donné à Marieville, ce 5c jour de janvier 1972.(Sceau) Le secrétaire-trésorier, (Seal) Mrs.Rita Ron deau, 44114-3-2-0 Mme Rita Rondeau.4114-3-2 Secretary-Treasurer. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.A 967 Municipalité Scolaire Protestante du Grand St-Martin dans les comtés de Laval et Fabre Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité scolaire ci-haut mentionnée, que les lots et parties de lots mentionnés dans la liste ci-jointe seront vendus à l'enchère publique, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures du matin, à l'école Hill-crest, 1125, boulevard Elizabeth, dans la cité de Laval, (Chomedey) pour défaut de paiement de cotisations et taxes municipales et scolaires, à moins que celles-ci ne soient payées, plus frais et intérêts, avant le 7e jour de mars prochain.Une enumeration abrégée des numéraux de cadastre des biens immobiliers a été autorisée par la Commission municipale de Québec.Protestant School Municipality of Greater St.Martin in the counties of Laval and Fabrc Public notice is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer of the aforementioned school municipality that the lots or parts of lots mentioned in the list attached hereto will be sold by public auction on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon in the Hillcrest School, 1125 Elizabeth Blvd., in the City of Laval (Chomedey), for municipal and school assessments and taxes unpaid unless the same be paid with costs and interest incurred before the 7th day of March next.An abridged enumeration of the cadastral numbers of immoveables has been authorized by the Québec Municipal Commission.Paroisse de Saint-Martin \u2014 Parish of Saint-Martin Taxes Taxes Nom du propriétaire Numéro du cadastre scolaires munie.Name of owner Cadastral number School Munie.taxes taxes K.Mayers.P.125-Mes.107.75' S.O., 263.4' N.O., 115.92' N.E.233.4' S.E.Bornes-Boundaries: S.O.Boul.Labelle N.O.124-10, N.E.143-P.-2 & 143-P.3.S.E.125-3 Mrs.M.Caron.114-174.L.Zbarsky.34-72.L.Zbarsky.31-74.T.Sigalas.P.-10-Mes.79.31' S.E., 112.7' S.O., 70' N.O., 150' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.Boul.Xevesque, S.O.10-404, N.O.10-P.-406 & 10-405, N.E.10-331 rue Carleton Birer Realty.82-76.J.Wasserman.30-180, 30-231.Codak Const.Co.30-9.Codak Const.Co.30-11.J.Loukidis.40-517.Mrs.I.Gelbart.26-124.N.Gorin.17A-126.N.Gorin.17A-127.N.Gorin.17A-128.16A72, 17A-129, 16A-73.Mr.S.Goldenberg.28-35.J.T.Baran.206A-206 & 207.P.Hazikelis.200-313, 314.P.Agelakos.200-243.N.Cotsomittis.200-240.E.Nadel.206 A-106 to 108.,.C.E.Lavoie.P.122.P.122-44, P.122-Mcs.95.54' S.E., 100' S.O.94.19' N.O., 113.14' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.Boul.Clermont, S.O.Boul.Antonio.N.O.122-P-44, N.E.P-122, P.122-P-44-Mes.94.19' S.E., 50' S.O.93.9' N.O., 50' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.P-122, S.O.Boul.Antonio, N.O.122-43.N.E.122-P-44.T.T.Fong &'al.P.115-Mes.48.5' Larg.N.O., 97' N.E., 92' S.O.Bornes-Boundaries: N.O.Boul.Notre-Dame, N.E.115-109, S.O.115-130, S.E.P-115, Supp.4,583 p.c.VV.L.Steele.73-620.Y.Kaplansky.66-64.Mrs.C.Binder.426-6 & 8.Codak Const.377-372.Mrs.R.Cutler.45-1-109, 66-1234.A.Vellopoulos.66-1120, 1121.Wvcliff Senior.574-4.I.Strobach.376-21.D.Freiman.376-39.G.Keitner.353-169 to 177.M.Federbush & al.352-1-99.L.E.Marvin I.T.P.372-Mes.90' N.O., 50.4 N.E.90' S.E., 51.4' S.O.¦* \u2022 Bornes-Boundaries: N.O.Boul.St.Martin, N.E.P.372, S.E; P.372, S.O.P.372.2,987\t19\tS 4,294.34 841\t,72\t2,022.66 1,388\t.09\t2,212.29 1,393\tS3\t2,197.42 952\t.98\t654.70 150\t67\t14S.36 106\t.12\t1,695.16 60\t.38\t253.28 1,949\t99\t394.96 1,383\t.94\t1,924.89 1,015\t.52\t 81\t79\t 80\t79\t 80\t79\t 1,351\t97\t3,274.48 245\t79\t202.11 159\t68\t200.11 339\t24\t122.23 74\t58\t71.03 160\t67\t74.86 1,756\t51\t2,319.74 403\t39\t523 91 952\t35\t1,702.24 340\t59\t 384\t.93\t858.88 169\t.13\t152.12 1,814\t08\t2,617.45 1.171\t.73\t1,965.36 573\t.61\t593.74 96\t.51\t99.36 210\t.10\t198.06 290\t.60\t316.80 83\t.06\t73.20 77\t70\t94.26 90S GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10k' année, n° l Nom du propriétaire Name of owner Numéro du cadastre Cadastral number Taxes scolaires School taxes Taxes munie.Munie, taxes N.Stermer, J.Richter & ai.P.698.- M Matar .P.595-Mes.86' S.E., 203' N.E., 239' 8.E., 2169 S.O.248.8' N.O.2301' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.P.595.N.E.P.595, S.E.Chemin St.Elzéar, 8.0.P-587, N.O.P-595 Hydro-Québec, N.E.P-595 I.Chochlacz.216-63.I.Chochlacz.216-64.Codak Const.Co.241-498,499.Montreal Land & Housing Corp.244-216.Codak Const.Co.241-498.497.Mme-Mrs.R.Gizariotis & al.244-243.243-113-.\u2022\u2022 \u2022 S Berkowits & al.246P.324-Mes.40.18 S.E., 29.67' S.E., 115'18' S.O.103' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.246-325 rue.SE.246-P-324, S.O.245-422, N.E.246-323.S Berkowits .v al.246-321 to 323-Mes.25' S.E.34.7' N.O.103' Prof.Bornes-Boundaries: S.E.246-325 rue.N.O.246-318 et 319.N.E.246-321, S.O.246-P.322, Mes.25' S.E., 34.7' N.O., 103' Prof.Bornes-Boundaries: 8.E.246-325 rue, N.O.246-319.N.E.246-P-322, 8.O.246-323.M.Chali.239-179.G.Keitner.244-265,266.R.Feldman.241-610,611.I.Fiksel.245-441,442.Mrs.F.Schreiber.245-463, 464.R.J.Sweeney.215-39.N.Kulyk.241-698.N.Kulyk.241-699.B.Jenkala & al.241-316.B.Jenkala at al.241-316.B.Mednick & al.216-74.B.Mednick &al.216-85.B.Mednick & al.217-27, 216A-75.B.Mtdnick & al.216-68, 216A-30.B.Mednick & al.216-86.B.Mednick &al.217-76, 77.B.Mednick &al.216-75.216A-31.B.Mednick 4 al.217-28.216A-76.M.Hering.216-11.M.Hering.215-12.M.Hering.216-13.Mrs.L.Louizos.246-444.M.Marcopoulos.261-446.B.Miro.261-579.North Star Housing Corp.200-281.International Const.Co.208-19.International Const.Co.94-18.International Const.Co.94-P.208-Mes.18.2' N.E., 94' S.E.36.3' S.O.Bornes-Boundaries: N.E.94-P.328.S.E.7th.Rue.S.O.Rue Hennessy.N.O.94-227.Residences Richelieu Inc.688:.Willart Const.Co.37-10.Jaymar Const.Ltd.P.48.46-P.2.P.48-Mes.159.1' N.O.77.86' N.E.34.16' E.S., 45.84' S.E., 89.79' S.E.128' S.O.Bornes-Boundaries: N.O.48.3' à-to 48-5.N.E.98th Avenue, E.S.48-57 & 48-68, S.E.48-67.S.E.48-66, S.O.46-P.2 46-P.2-Mes.68.9' N.O., 150.82' S.O., 66.3' S.E., 40.34' E.10.03' S.E., 128' N.E.Bornes-Boundaries: N.O.46-2-22 & 23, S.O.46-1-22, S.E.46-2-24, E.46-2-26.S.E.46-2-26, N.E.P.48.Brian Enterprises Ltd.31-61.Brian Enterprises Ltd.31-50.Normandie Dev.Inc.13-37, 16-38.Normandie Dev.Inc.16-37.Ste.Thérèse Housing & Al.P.7- 97' N.O.3476' N.E., 297.3' S.E., 3260.4' S.O.220' N.O., 225' S.O.Bornes-Boundaries: N.O.Boul.Levesque.N.E.P.7.S.E.Rivière des Prairies, S.O.7-1, N.O.P.7.S.O.P.7.Hanover Const.Ltd.P.30-Mes.116.98' N.O.402-12' N.E.110.51' S., 23.65' 8.O.266.49' S.O.Bornes-Boundaries: N.O.P-30, N.E.30-12 à-to 16 A P-30.8.P-30 (2).8.O.P-30 (2).S.O.P-30 (2).Supp.33.627 pi-ca.2,164.32 2,500.01 S 3,655.82 803.65 76.40 75.24 376.13 144.75 315.64 73.48 89.78 367.10 62.81 287.97 123.18 237.91 124.62 128.59 192.78 184.90 204.84 153.77 169.59 191.35 222.68 176 38 220.74 371.58 221.84 279.87 153.72 144.08 185.03 290.71 170.47 91.34 379.80 421.35 136.22 66.14 520.39 203.00 511.65 345.26 330.68 138.81 191.02 4,535.18 174.16 50.63 176.05 100.04 44.51 147.95 52.60 256.91 43.97 456.74 242.04 81.20 180.10 230.66 193.86 150.86 824.12 893.11 932.80 824.12 1,167.41 2.030.96 1.450.12 1.191.31 983.48 1,050.15 933.06 850.80 198.11 150.94 465.98 1,478.92 618.94 322.50 2,744.29 1,650.67 3.062.12 2,559.31 1,551.69 465.75 606.19 5,629.20 797.85 9,281.06 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 969 Taxes Taxes Nom du propriétaire Numéro du cadastre scolaires- munie.Name of owner Cadastral number School Munie.taxes taxes P.30-Mes.58.49' N.O., 256.49' N.E.23.65' N.E.110.51' N.O., 61.61' N.E., 146.51' S.226.14' S.O.Bornes-Boundaries: N.O.P-30 (1).N.E.P-30 (1), N.E.P-30 (1), N.O.P-30 (1), N.E.30-20, S.P-30, S.O.P-30.Supp.20,856 pi.ca.\u201e .,.Hanover Const.Ltd.P.30-Mes.226.14' N.E., 70.93' N.E.N., 146.51' N.$ 902.83 S 1,567.51 149.78' N.E.61.30' N.E., 455.63' S.27.55' S.71,93' S.O.142.2' O.223' S.O.O.-N.O.O., 20.35' O.Bornes-Boundaries: P-30 rue projetée.N.E.N.P-30 rue projetée, N.P-30 rue projetée, N.E.P-30, 30-23, N.E.30-P-24, S.30-232, S.30-232.S.O.27-89, O.P-30.S.O.-O.N.O.-O.30-255, O.30-255.Supp.109,173 pi.ca.Mes.479' N.175.55' N.E.103.95' S.351.8' S.220.65' S.O.Bornes-Boundaries: N.30-232, N.E.30-P.24, P-25, P-30, S.4th.rue.S.4th.rue, S.O.27-88.Supp.pi.ca.75, 902.International Const.Inc.94-186.128.76 560.21 International Const.Inc.94-187.127.16 558.07 International Const.Inc.94-188.133.02 , 677./6 Mme T.Alvi.10-463.1,033.44 1,971.66 MmeT.Alvi.10-452.1.748.34 2.109.69 Normandie Dev.Inc.10-192.12-3.163.33 '-490./4 Normandie Dev.Inc.10-191.12-4.144.79 1,19-59 Back River Inv.& Al.10-89 .200.51 1.168.03 Hanover Const.Ltd.30-195 .239.68 W6.44 Hanover Const.Ltd.30-194.117.75 82.21 Back River Inv.10-252,267 .82.55 101 13 Back River Inv.10-186.75.46 80.22 Normandie Dev.Corp.12-78.§7.26 676.42 Normandie Dev.Corp.12-77.81.50 660-70 Normandie Dev.Corp.12-76.81.70 622.70 Normandie Dev.Corp.12-75.72.32 520.39 Normandie Dev.Corp.12-74.65.55 497.23 Normandie Dev.Corp.12-73.H'H SH'S Back River Inv.12-72.154.09 213.93 Back River Inv.10-148 .62.87 179.09 Home Const.Co.10-181.217.83 412.92 Home Const.Co.10-180.193.21 203 64 Home Const.Co.10-179.J93.2 203.64 Home Const.Co.10-177.193.51 203.64 Home Const.Co.10-195 .221.39 606.58 Home Const.Co.10-144.193.22 363.08 Home Const.Co.10-145.220.12 387.31 Home Const.Co.10-168,12-68 .275.04 484.83 HomeConst.Co.10-169,12-69.221.3 355.59 HomeConst.Co.10-170,12-70 .221.13 404.44 HomeConst.Co.10-173 .302.51 344.60 HomeConst.Co.10-174 .270.58 304.22 HomeConst.Co.10-176 .257.80 289.11 Home Const.Co.10-176.285.49 322.42 Home Const.Co.10-146.194.65 205.31 Home Const.Co.10-147.201.32 224.02 CraftbuUt Const.Ltd.P.12-Mes.189.19'S.O.37.65'N.99.71'E.4 N.14.91' 51.95 185.54 N.E.60.05' S.E.Bornes-Boundaries: S.O.10-172, N.rue Campbell.E.& N.rue Campbell, N.E.rue Campbell, S.E.P-12.Mes.58.19' S.E.17.27' S.O.60.05' N.O.Bornes-Boundaries: S.E.12-71, S.O.10-171.N.O.P-12.Back River Inv.Inc.10-172.40.31 90.89 HomeConst.Co.10-182 .240.66 605.41 HomeConst.Co.10-183.193.26 208.94 HomeConst.Co.10-184.93.25 208.94 HomeConst.Co.10-185.103.11 207.43 Dunbar Inv.Corp.10-149.62.87 909.09 Dunbar Inv.Corp.10-160.61 87 .179.09 Dunbar Inv.Corp.10-161.77.17 218.38 Dunbar Inv.Corp.10-152 .68.14 193.63 Dunbar Inv.Corp.10-183 .59.25 171.19 Dunbar Inv.Corp.10-154 .56 3 162.87 Dunbar Inv.Corp.10-155 .56 31 162.87 Dunbar Inv.Corp.10-156 .50.96 162.87 Dunbar Inv.Corp.10-157 .60.31 162.87 Dunbar Inv.Corp.10-168 .67.64 166.60 > 970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10k' année, n° 4 Taxes Taxes Nom du propriétaire Numéro du cadastre scolaires munie.Name of owner Cadastral number School Munie.taxes taxes Dunbar Inv.Corp.10-159.- HomeConst.Co.10-167.HomeConst.Co.10-166.HomeConst.Co.10-165.Mercedes Inv.Corp.10-164.Back River Inv.10-163.Back River Inv.10-160.Dunbar Inv.Corp.10-162.Dunbar Inv.Corp.10-161.Normandie Dev.Inc.12-84.Normandie Dev.Inc.12-85.Normandie Dev.Inc.12-86.Normandie Dev.Inc.12-87.Normandie Dev.Inc.12-92.Normandie Dev.Inc.12-88.Normandie Dev.Inc.12-83.Normandie Dev.Inc.12-82.Normandie Dev.Inc.12-81.Normandie Dev.Inc.12-80.Normandie Dev.Inc.12-79, 10-188.Home Const.Co.10-143.Home Const.Co.10-142.Back River Inv, Inc.& oi.10-141.Dunbar Inv.Corp.& al.10-137.Normandie Dev.Inc.& al.12-61.Normandie Dev.Inc.& al.12-60.Normandie Dev.Inc.& al.12-59.Normandie Dev.Inc.&al.12-58.Normandie Dev.Inc.& ai.10-44, 12-57.Normandie Dev.Inc.& ai.10-43.Normandie Dev.Inc.& ai.10-47.12-54.Normandie Dev.Inc.& al.40-46, 12-55.Normandie Dev.Inc.& al.10-45, 12-56.Normandie Dev.Inc.& a!.10-48.HomeConst.Co.10-41.Home Const.Co.10-39.HomeConst.Co.10-49.Home Const.Co.10-50.Home Const.Co.10-51.Back River Inv.Inc.leal.10-38.Back River Inv.Inc.& ai.10-52.Back River Inv.Inc.& al.10-119, 12-63.Normandie Dev.Corp.& ai.12-37.Normandie Dev.Corp.& al.12-25.Normandie Dev, Corp.& al.12-26.Normandie Dev, Corp.& al.12-27.Normandie Dev.Corp.& ai.10-101, 12-31.Normandie Dev.Corp.& ai.12-30.Normandie Dev.Corp.& al.12-29.Normandie Dev.Corp.& ai.12-28.Normandie Dev.Corp.& ai.12-44.Normandie Dev.Corp.& al.12-45.Home Const.Co.10-40.Normandie Dev.Corp.& a!.12-46.Normandie Dev.Corp.& ai.12-53.Normandie Dev.Corp.&al.12-52.Normandie Dev.Corp.& al.12-51.Normandie Dev.Corp.& ai.12-50.Normandie Dev.Corp.& ai.12-49.Normandie Dev.Corp.& ai.12-48.HomeConst.Co.10-112.Home Const.Co.10-111.Home Const.Co.10-110.Home Const.Co.10-109.Back River Inv.Inc.& ai.10-70.Back River Inv.Inc.& ai.10-69.,.Back River Inv, Inc.& al.10-68.Dunbar Inv.Corp.& al.10-33.Dunbar Inv.Corp.& al.10-118.Gary Realties Inc.28-91.S & M Const.Co.30-127.Normandie Dev.Inc.13-27, 16-27, 17-33 .Normandie Dev.lac.10-451, 13-14.$ 69\tSU\t% 197.46 319\t,36\t375.96 216\t.82\t265.91 341\t.38\t408.47 86\t.24\t235.94 71\t.00\t206.47 74\t.46\t203.98 58\t.31\t162.87 69\t.20\t182.85 til\t.01\t481.11 77\t.17\t242.59 02\t.60\t190.71 63\t.27\t190.71 93\t.93\t227 11 63\t.83\t194.85 70\t.27\t912.23 70\t.90\t891.29 64\t.62\t827.91 56\t.31\t798.95 101\t94\t1,162.42 194\t.43\t420.70 200\t.84\t474.31 61\t91\t608.51 54\t13\t89.65 85\t00\t831.91 102\t66\t926.67 102\t.40\t926.67 85\tno\t831.91 86\t00\t656.52 85\t67\t831.91 126\t60\t738.23 161\t40\t791.78 181\t:is\t847.94 94\t98\t798.15 192.\t49\t435.81 200\t34\t593.10 192.\t48\t598.92 192\t48\t267.91 199\t75\t620.29 91.\t27\t591.56 139\t04\t608.90 2,418.\t60\t6,478.94 123\t63\t912.30 122\t20\t1,226.56 101\t65\t851.18 123\t11\t1,226.56 85\t88\t1.019.94 85\t88\t1,199.04 S5\t88\t835.92 86\t79\t835.92 101\t02\t1,155.87 85\t(10\t729.76 192.\t49\t492.68 88\t24\t1.082.14 so,\t06\t910.16 78.\t02\t675.80 78.\t62\t726.91 106.\t33\t919.37 96.\t08\t872.75 95\t43\t801.17 233\t79\t697.68 192\t50\t606.11 192\t60\t598.91 191\t38\t598.91 103\t03\t822.36 85\t00\t587.89 101\t77\t821.59 118\t95\t686.06 146\t33\t296.76 11\t67\t50.63 608\t00\t870.46 1,966\tS4\t 38.\tGO\t61.98 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 971 Taxes Taxes Nom du propriétaire Numéro du cadastre scolaires munie.Name of owner Cadastral number School Mimic.taxes taxes Nu-Vel Homes Inc.13-28.$ 77.87 S 218.42 Nu-Vel Homes Inc.13-29.77.28 223.18 Nu-Vel Homes Inc.13-30,16-28 .77.28 223.56 Nu-Vel Homes Inc.16-29.77.23 223.60 Nu-Vel Homes Inc.16-30,17-34 .77.23 223.50 Nu-Vel Homes Inc.17-35 .78.53 231.91 Nu-Vel Homes Inc.17-36 .90.59 362.67 Nu-Vel Homes Inc.17-37.82.74 237.29 Nu-Vel Homes Inc.17-38 .82.74 238.82 Nu-Vel Homes Inc.17-39 .89.90 359.44 Nu-Vel Homes Inc.17-45.84.18 773.31 Nu-Vel Homes Inc.17-46.78.66 508.54 Nu-Vel Homes Inc.13-34.82.74 234 97 Nu-Vel Homes Inc.13-35 .76.61 227.65 Nu-Vel Homes Inc.13-36,16-34.75.21 226.17 Nu-Vel Homes Inc.16-35.73.64 269.44 Nu-Vel Homes Inc.16-36,17-43.'.72.38 222.78 Nu-Vel Homes Inc.17-44.73.44 222 78 Nu-Vel Homes Inc.13-33.75.21 223.06 Nu-Vel Homes Inc.13-32.77.23 223.60 Nu-Vel Homes Inc.13-31,16-33._._ 77.23 223.60 Nu-Vel Homes Inc.16-32 .77.23 290^32 Nu-Vel Homes Inc.16-31,17-41.77.23 223.60 Nu-Vel Homes Inc- .17-40.79.32 215 24 Standard Credit Corp.209-104 .92.41 110 83 Standard Credit Corp.209-56.342.14 190.15 Codak Const.160-326 .994.30 564.65 Centennial Dev.Corp.115P.8-Mes.50'largeur.90'profondeur.Bornes-Bounda- 298.57 1,065 41 ries: N.E., 115-P-8, S.O., 94-P.40, N.O., 115-P-7.S.E., P-115.Centennial Dev.Corp.115P.7-Mes.50' largeur, 90' profondeur.Bornes-Bounda- 296.57 1 065 41 ries: N.E., 115-P-7.S.O.94-P-39, N.O., P-115, S.E., 115-P-8.Centennial Dev.Corp.115P.6-Mes.50' largeur, 90' profondeur.Bornes- 329.01 1,144 07 Boundaries: N.E.115-P-6.S.O.94-P-37 et P.38, N.O.P-115, S.E.P-115.Shorecrest Homes Ltd.66-726.169.00 1,050.43 W.Weber.73-93.115.90 «56.84 Hanover Const.Ltd.66-120 .258.72 1,057 75 Maywood Inv.Corp.66-881.45-1-87 .318.47 1,837.22 Four Star Enterprise Ltd.& al.66-1014 .271.97 1,087.78 Four Star Enterprise Ltd.& al.66-1013 .267.35 1,093 54 Four Star Enterprise Ltd.& al.66-826 .268.97 1,101 83 W.Weber.,- 73-100.125.29 328.64 A.Rudner.73-82.131.78 344 62 A.Rudner.73-83.131.78 344 62 A.Rudner.73-84.127.29 332 08 Mrs.C.Binder.426-11 & 12.212.01 476.57 R.Ross.426-13.124.68 93.91 R.Ross.426-14.122 60 93.91 R.Ross.426-15.136 54 107.95 Mrs.C.Binder.426-21.120 02 129 71 Laurence Realties Ltd.P.380-Mes.264.28' S.E.31.41' S.& O.33' S.E., 1,192.98 5,363 40 1020' S.O.306' N.O.940' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.380-175 rue, S.4 O.380-175 rue.S.E.rue Murphy.S.O.P.380.N.O.P.380, N.E.lot 377.O.Hébert.380-204 .367 13 G.Hébert.380-205 .370!o3 Jaymar Const.Ltd.495-118 .688.74 1,410 48 Jaymar Const.Ltd.495-119 .674.20 890.65 Mrs.C.Binder.426-6 & 7 .415.92 611 66 Midlick Realties Ltd.P.490-Mes.223.7'S.E., 222'N.O., 2453'S.O.7,213.26 9.432 10 2457' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.P-490, N.O.580 & 579, S.O.Lot 491, N.E.Lot 480.Four Star Enterprise Ltd.66-32 .264.02 1.481 41 Centennial Dev.Corp.94-739 .209.83 1,748^00 Centennial Dev.Corp.94-738.184.03 967 83 Centennial Dev.Corp.94-737.184.03 967 83 Centennial Dev.Corp.94-736.184.03 967\"83 Centennial Dev.Corp.94-735.184.03 967 83 Centennial Dev.Corp.94-734.184.03 967 83 Centennial Dev.Corp.94-733 .209.54 1.565 00 Codak Const.66-1010.'.920.98 2',0U9 69 972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10h' année, n° 4 Nom du propriétaire Name of owner Numéro du cadastre Cadastral number Taxes scolaires School taxes Taxes munie.Munie, taxes Jaymar Const.Ltd.Centennial Dev.Corp.Centennial Dev.Corp.Centennial Dev.Corp.Centennial Dev.Corp.Centennial Dev.Corp.Centennial Dev.Corp.Centennial Dev.Corp.Centennial Dev.Corp.Centennial Dev.Corp.Centennial Dev.Corp.Jaymar Const.Ltd.Jaymar Const.Ltd.Jaymar Const.Ltd.Jaymar Const.Ltd.Individual Inv.Corp.Issie Caron.Hanover Const.Ltd.P.D.& Son Co.Ltd.P.D.& Son Co.Ltd.Roma Realties Inc.Laval Industrial Park.Four Hundred Realties & Meinour Corp.Four Hundred Realties & Melbour Corp.A.Maggio.Normandie Const.Inc.Normandie Const.Inc.Normandie Const.Inc.Normandie Const.Inc.Normandie Const.Inc.J.C.Mailloux Const.Ine.J.C.Mailloux Const.Inc.J.C.Mailloux Const.Inc.Immeubles Laurence Ltée.Midlick Realties Ltd.Midlick Realties Ltd.J.Wasserman.Midlick Realties Ltd.Shillwood Inc.495-145.94-743.94-741.Shillwood Inc.Laval Industrial Park Ltd.94-742.94-744.94-745.94-747.94-716.94-717.94-718.94P.37-Mes.50' NO.50' S.E., 100\" N.E., 100' S.O.BorHes-Boundaries: N.O.94-P-37, S.E.94-P-37.N.E.115-P-5 & P-115.S.O.94-P-37.495-148.495-112.495-122.495-54.68-84.68-85.:.66-1012.69-31.69-32.507-P.176.P.614, P.615.P.614-Mes.301.6' NO.436.89' S.O., 358.38' S.E.250' N.E.Bornes-Boundaries: N.O.Par Ste.Rose, S.O.Lot 612, S.E.614-2, N.E.P.615.P.615-Mes.266' N.O.250\" S.O., 319.40\" S.E.42.35' N.E.Bornes-Boundaries: N.O.Par Ste.Rose, S.O.P-614, S.E.616-2, N.E.Chemin public.352-1-54.352-1-100.'.353-149.350-248.350-259.350-260.350-265.350-264.349-284-1 to 3.349-283-1 to 4.350-267.350-266-1 to 3.P.373-Mes.290.78 SO.430' N.E.284.14' S.E.430\" S.O.Bornes-Boundaries: N.O.P-373.N.E.P-372.S.E.P-373.S.O.P-374.P.577.P.578.P.577-Mes.591' S.E., 1232' S.O., 697' N.O.1232' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.Lot 578.S.O.Lot 576, N.O.P-577, N.E.Lot-581.P.578-Mes.443' S.E.138.6' S.E.2590' S.O.591' N.O.2415' N.E.175' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.Rang Petit Bois.S.E.P-678, S.O.Lot 676, N.O.Lot 577.N.E.Lot 580 & 581.N.E.P-578.P.676-Mes.298' S.E., 3822' S.O., 297' N.O.3822' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.Rang Petit Bois.S.O.P-576, N.O.P-576.N.E.Lot 577 & 578.P.581.P.579-Mes.836.5' N.O.641' N.E., 875' S.E.573' S.O.Bornes-Boundaries: N.O.Chemin public.N.E.Lot 580.S.E.Lot 495, 491.490, S.O.Lot 579.P.568, P.569._.P.568-Mes.285.9' S.E., 2193' N.E., 285.9' N.O.2177.52' S.O.Bornes-Boundaries: S.E.Boul.Cleroux.N.E, Lot 571.N.O.Lot 669, S.O.Lot 567.P.569-Mes.285.9' S.E,.633.36' S.O.2SS.8' N.O., 642.24' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.Lot 568.S.O.Lot 567.N.O.P-569.N.E.Lot 670.P.568-Mes.285.9' N.O.2195' N.E.280' S.E., 2490,6' S.O.Bornes-Boundaries: N.O.Boul.Cléroux, N.E.lot 571.S.E.lot 509, S.O.lot 567.P.614, P.615.P.014-Mes.80.92' O., 32.50' S.111.42' N., 123.39' N.E., 237.43' S.O.Bornes-Boundaries: O.614-1.3.014-3, N.614-3.N.E.P-616.S.O.Autoroute.528.14 315.75 359.81 315.80 315.75 315.75 323.70 392.54 334.83 384.59 429.92 438.12 506.74 583.48 470.37 146.61 52.76 196.38 1.179.17 1,190.11 1.243.29 441.44 57.92 40.05 129.06 727.96 33.62 33.62 47.03 44.53 nn so 53.72 49.05 1.181.95 2.597.01 1,240.44 1,774.07 1,240.44 1,240.44 1,240.44 1,670.11 1,818.04 1,283.92 1,283.92 2.037.60 1,656.46 1,531.54 1,842.10 1,785.62 381.19 60.98 500.50 1,542.82 1,662.98 2,306.83 462.15 124.78 88.15 118.44 1,394.85 233.77 411.75 624.29 229.96 160.38 160.38 6,309.37 13,577.48 4,755.15 7,321.22 555.08 819.29 2,447.11 3,554.67 2,269.54 1,370.63 1.192.88 1.191.99 167.31 119.07 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 973 Taxes Taxes Nom du propriétaire Numéro du cadastre scolaires munie.Name of owner Cadastral number School Munie.taxes taxes P.165-Mes.141.44' N., 67.95' S.E., 123.39' S.O.Bornes-Boundaries: N.615-3, S.E.P-616.S.O.P-614.Midlick Realties Ltd.581-P.2-Mes.290.7' N.O.,289.9'S.E.2495' N.E.,2571.6' $ 4,900.65 $ 5.796.53 S.O.Bornes-Boundaries: N.O.Rang.St-Elzéar, S.E.Lot-580, N.E.581-1, S.O.577 & 578.R.Koning.001-29,30 .43.87 34.18 L.Albanese.353-557.19.80 Normandie Const.Inc.353-399.104.00 921.91 Normandie Const.Inc.353-401.89.66 888.46 Normandie Const.Inc.353-402.89.66 888.46 Normandie Const.Inc.353-403 .89.66 888.46 Normandie Const.Inc.353-404 .90.35 888.46 Normandie Const.Inc.353-405 .53.92 888.46 R.Lafrance.353-400 .639.89 618.57 L.DiCera.353-686 .319.47 580.23 L.Chiasson.353-311.35.60 M.Lobel & Al.376-1.3.797.21 12,340.81 J.Giannoulis.337-641.306.22 257.38 Luc Adam.336-198 .302.47 J.Lapointe.337-621.31.35 86.90 Alliance Land Holdings Ltd.252-343,252-344 .487.64 2,728.46 Alliance Land Holdings Ltd.252-345, 252-346 .489.94 2.538.55 Alliance Land Hoi dings Ltd.252-347,252-348 .487.64 2,537.96 Alliance Land Holdings Ltd.252-349,252-350 .406.77 2,409.37 La Grange de Mon Oncle Ltée & Al.252-327,328.701.39 3,940.51 La Grange de Mon Oncle Ltée & Al.252-329,330 .612.96 2,526.47 La Grange de Mon Oncle Ltée & Al.252-331.332.632.60 2,598.19 La Grange de Mon Oncle Ltée & Al.252-333,334 .677.59 3,390.60 G.Desiardins.252-316.8.07 476.60 G.Desiardins.252-317.36.23 1,896.43 A.Lussier.252-444 .221.96 168.62 Alliance Land Holdings Ltd.& Al.252-281,282 .659.13 3,720.16 Alliance Land Holdings Ltd.& Ai.252-283.241\"37.1.181.99 Sylvestre Petroleum Inc.255-244, 245.16.18 Yorktown Budding Corp.252-267.67.68 2,626.06 D.Barletta & G.Marchetta.259-P.333-Mes.100' N.E., 93.58' S.O., 224.9' N.O., 36.22 1,643.32 190.2' S.E.Bornes-Boundaries: 259-332 Rue N.E., P.259 S.O., 259-P.333 N.O., 259-99.S.E.Miadel Dev.Corp.259-334.40.76 2,274.36 Miadel Dev.Corp.260-672,259-335 .31.05 2,416.92 Miadel Dev.Corp.259-336,260-671.35.24 2,649.08 Miadel Dev.Corp.259-337,260-670 .37.86 2,719.47 Miadel Dev.Corp.259-338.260-668 .35.86 1,994.02 H.Cardinal.271-947 .866.43 716.08 J Dutil .267-122,268-250.2,131.12 1,422.15 J Dutil .268-252.2,202.21 1,417.88 j'Dutil \".\".I.268-254 .2,263.36 1,424.31 Cartier Holding Inc.260-P.806, 261-P.739.3,933.63 18.676.28 8 260-P-806-Mes.155.2' N.O., 720.56' N.E., 242.7' S.E., 681.35' S.O.31.09' O.Bornes-Boundaries: N.O.260-193, N.E.261-P-739, S.E.260-P-806, S.O.260-P-805.O.260-P-805.Supp.151,341 pi.ca.261-P-739-Mes.371.75' N.O., 2S' N., 476.96' N.E., 28.74' N.E., 400.24' E., 28.37' E.294.09' S.E., 121.73' S.O.44.37' S.E., 720.56' S.O.Bornes-Boundaries: N.O.261-738 rue, N.261-738 rue, N.E.261-184 rue, N.E.261-181 rue, E.261-181 rue, E.261-180 rue, S.E.261-180 rue.S.O.261-P-739, S.E.261-P-39, S.O.260-P-806.Miadel Dev CorO .260-665.17.97 1,121.03 Miadel Dev Corp '.259-331,260-666.21.16 1,073.66 MHdc Dev Corp .260-P.669-Mes.112' N.O.100.95' N.E.88' N.O.43.18 1,739.46 Miaoei uev.oorp.j4g Q5, ^ E WQ, 25Q, g Q Borne8.Boundaries: N.O.260-667 rue, N.E.260-P-669.N.O.260-P-669.N.E.260-673 rue.S.E.260-670, S.O.260-668.Supp.41,144 pi.ca.M Asselin .273-579.11.46 198.19 Les Placements Port Royal Inc.264,126.l'8|ï|2 2,220.33 p Riais .275-632.2o.85 LesrîStreprises'victorin'lnc.P.271-Mes.457.2' N.O., 12,7.9' N.E., 374.6' S.E., 126' 74.34 18,442.30 Les entreprises victo g,Q, Bornes-Boundaries: N.O.271-629 à-to 636, 561, 691.694, N.E.271-589, S.E.Boul.Cartier, S.O.P.269. 974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.£9 janvier 197£.10i' année, n° A Taxes Taxes Nom du propriétaire Numéro du cadastre scolaires munie.Name of owner Cadastral number School Munie.taxes taxes A Bentivogli .256-542 à-to 555, 558 à-to 566.$1.315.66 $ 912.63 Immeubles Lav.Inc.252-106.107.433.51 2,833.08 R Ross .424-15 .23.00 103.17 R Ross .424-16 .23.00 99.17 R Ross .V- ¦¦ 424-18 .23.00 99.17 R Ross .424-19 .23.00 99.17 RRoss .424-20.23.77 98 69 J.Dutil .265-120 .2.150.94 1.643.70 J Dutil .265-118,266-90.2,130.68 1,409.39 J.Dutil.267-121.2,130.68 1.409.39 Montreal Land & Housing Corp.P.244.903.01 1,132.46 Paroisse de Ste-Dorothée \u2014 Parish of Ste.Dorothée Forward Dev.Corp.P.34-Mes.305'N.O.1190'N.E., 602.92'S.& O., 250.7' $6.115.70 $17,681.06 N-, 389.5' O., 20.7' O., 121.03' N.O.200' S.O.Bornes-Boundaries: N.O.Rue Mercure.N.E.lot 33, S.& O.34-90 à-to 100.N.P-34 & P-34 Boul.Samson, O.P-34 Boul.Samson, 0.P-34 Boul.Samson, N.O.P-36, S.O.P-35.P.34-Mes.150.7' S.E., 325.25' O., 253' S.O., 93.75' N.O., 67.05' N.E., 425.56' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.P-34.O.34-106.34-109-2 & 3,34-110-1 à-to 3,34-111-1 & 2.34-112-1 & 2.S.O.P.36, N.O.P.35, N.E.P.34 Boul.Samson.N.E.P.34 Boul.Samson.P.34-Mes.22' 0.30' N.30' N.E.Bornes-Boundaries: O.34-P-50.N.34-P-50.N.E.34-138.P.34-Mes.30' S.E.81.27'.s.e.125.4' S.O., 78.4' N.O.121.93' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.Route 38, S.E.Route 38, S.O.34-138.N.O.P-34, N.E.34-137.P.34-Mes.230.62' S.E., 21.47' O., 83.4' S.O., 148.35' N.O., 60' N.E., 60' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.34-134, P-34, 34-P-138, O.34-9, S.O.34-9, N.O.Rue Lajeunesse, N.E.Lot 33, N.E.34-4.Forward Dev.Corp.34-42.126.97 262.70 Forward Dev.Corp.34-43.137.79 493.63 Forward Dev.Corp.34-44.141.44 513.18 Forward Dev.Corp.34-45.141.44 625.98 Forward Dev.Corp.34-46.130.58 489.26 Forward Dev.Corp.34-47.130 58 490.36 Forward Dev.Corp.34-48.130.58 489.08 Forward Dev.Corp.34-49.137.79 620.59 Forward Dev.Corp.34P50-Mes.60.5'S.E., 125.06'SO., 2.31'N.O.50.56' 121 10 502.71 N.O., 43.19' N.E., 30' S., 22' E.45' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.Route 38, S.O.34-49, N.O.34- P-10.N.O.34-P-9 et P.10, N.E.34-138, S.P.34, E.P.34, N.E.34-138.Forward Dev.Corp.P.35-Mes.580' N.E., 580' S.O., 150' N.O., 150' S.E.527.70 8,809 49 Bornes-Boundaries: N.E.35-5 à 13.S.O.Boul.Samson, N.O.35-14.S.E.35-4.Jardins Ste.Dorothée Inc.36-161, 162.35-166 to 172, 35-175 to 177.1.385.41 2,035.29 Jardins Ste.Dorothée Inc.36-55 .784.98 1,497.29 Emile Pesant Inc.P.36 .280.42 73 83 Emile Pesant Inc.36-393.196.85 1,017.77 Emile Pesant Inc.36-394.179.52 497.40 Emile Pesant Inc.36-396.179.52 497^40 Emile Pesant Inc.36-396.179 28 497^40 Emile Pesant Inc.36-397.179.27 497^40 Emile Pesant Inc.36-398.179 27 497 40 Emile Pesant Inc.36-390,37-303.'223'10 880*71 Emile Posant Inc.36-391.37-304 .223 10 ffi! 71 Emile Pesant Inc.36-392,37-306 .224 10 639 71 Ste.Dorothée Dev.Corp.36-82,83,84.116.13 3,488 40 Ste.Dorothée Dev.Corp.36-151.233 13 4 077 22 Ste.Dorothée Dev.Corp.36-223 .277.15 l'73l 20 Ste.Dorothée Dev.Corp.37-90-1.151.02 '328 98 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.m.No.L 975 Nom du propriétaire Name of owner Numéro du cadastre Cadastral number Taxes scolaires School Taxes munie.Munie.taxes\t\ttaxes 1,602.\t80 $\t17,419.82 254.\t30\t361.62 735\t03\t3,644.18 10.\tII\t 190.\t03\t424.68 1,193\t86\t1,559.70 170\t55\t1,157.24 1,077.\t07\t735.72 6,311.\t73\t4,041.50 Ste.Dorothée Dev.Corp.Les Entreprises Comet Ltée.Daroll Const.Ltd.Succession J.Avard.Bala Dev.Corp.Cajy Inc.Codak Const.Co.Les Placements Feuille Desrables Inc.Arrowood Inc.Ltd.& al.Brookmere Dev.Corp.Emile Pesant Inc.Emile Pesant Inc.Emile Pesant Inc.P.41, 39-109.Mes.486.5' S.O.23.8' S.O., 90' S.E., 41.2' S.O., 538.3' N.E., 102' N.O., Bornes-Boundaries: S.O.41-2 rue, S.O.41-1 rue, S.E.41-26, S.O.41-26, N.E.39-109, 110, 115, 119, N.O.41-8 et 9.37P.19, 37P.89.39-339.3q_2 42-29 \"to8'i.\"'\"\"\"\"\"\"''\"*\"!.' '.'.'.47-1-6.47-2-15.P.96.P.105, 106 P.2, 106-P-2-Mes.60.6' S.E., 76.8' S.E,, 120' S.O., 168' S.O.4336.7' S.O., 48' N.O.1152' S.O.144' N.O., 8696.2' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.Chemin Principale, S.E.106-P- 2 et 106-P-3, SO.106-P-2, S.O.106-P-3, S.O.P-105, N.O.P-105, S.O.P-105, N.O.P-196 et P.199, N.E.106-1.P.105-Mes.107.6' S.E., 4493' S.O., 164' N.O., 1152' N.E., 48' S.E., 4336.7' N.E.Bornes-Bundaries: S.E.P.105.S.O.P-105, N.O.Lot 199, N.E.106-2, S.E.106-2, N.E.106-P-2 et 106-P-3.P.156-Mes.319' N.O., 679.7' N.E., 130' S.E., 224' S.O.348.6' S.O.Bornes-Boundaries: N.O.Chemin Public, N.E.Lot 155, S.E.P-156, S.O.Chemin Public, S.O.P-156.Supp.3.41 arp.ca.P-156-Mes.252.5' S.O., 187.5' S.O., 3722.8' S.O., 1000'% S.O., 225' S.O., 223' N.O., 184.8' N., 4730.6' N.E.Bornes-Boundaries: S.E.chemin public.S.E.P-156, S.O.P-156, S.O.P-157, S.O.P-156, N.O.P-156, N.par Ste.Rose.N.E.P-155.Sup.31 arp.ca.36-414,415.36-416.:.36-301.2,639.34 249.66 143.24 223.32 144.67 2,033.97 1,003.00 1,241.22 Le secrétaire-trésorier, 44153-3-2 F.Walther.Municipalité du comte de Portneuf Avis public est par les présentes donné par Vauque-lin Frenette, secrétaire-trésorier, que les immeubles ci-après mentionnés seront vendus à l'enchère publique, au village de Cap-Santé, au lieu où le conseil de Comté tient ses sessions, au numéro 300 Rte Nationale, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de Pavant-midi, à défaut du paiement des taxes municipales et scolaires et autres redevances, ainsi que des frais encourus.F.Walther, 44153-3-2-o Secretary-Treasurer.Municipality of the county of Portneuf Public notice is hereby given by Vauquelin Frenette, Secretary-Treasurer, that the immoveables under-mentionned shall be sold by public auction, in the village of Cap-Santé, where the council of the county of Portneuf holds its sittings, at 300 Rte Nationale, THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for non-payment of municipal and school taxes and other dues, as well as cost incurred.Municipalité de Deschambault (paroisse) \u2014 Cadastre de Deschambault Municipality of Deschambault (parish) \u2014 Cadastre of Deschambault Taxes Taxes num.scol.Propriétaire No du cadastre et description et int.et int.Total Owner Cadastre No.and description Mun.School taxes taxes and int.and int.Beaulieu.Sylva P.231 S 52.00 t 228.54 S 280.64 976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier Me, 10A- année, n' A Taxes Taxes mun.scol.Propriétaire No du cadastre et description et int.et int.Total Owner Cadastre No.and description Mun.School taxes taxes and int.and int.Gosselin, Fernand.P.183, rg.Lachevrotière.Borné-bound.S $ 2.00 S 52.97 $ 54.97 Mme-Mrs.Philias Trottier, N.& 0/W;, F.Masson, E.chemin public Road.A distraire-to withdraw 40% vendu à-sold to F.Masson.Succ.-est.Emilien Gosselin.P.183, rg Lachevrotière.Borné-bound.E.2.00 2.00 chemin public Road, S.& O./W.Fernand Masson.A distraire-to withdraw 50% vendu à-sold to Fernand Masson.Boulay, Ghislain.P.184, rg.Lachevrotière.Borné-bound.par- 37.64 76.03 113.67 by Rte Arcand Rd & Riv.Pinsonnault, Guy.Bât.en ruine-build.falling in ruins sur-on 2.00 2.00 lot 183.Municipalité de Montauban-Ies-Mines \u2014 Cadastre de Saint-Ubald Municipality of Montauban-les-Mines \u2014 Cadastre of Saint-Ubald Parent, Lucien Parent, Emilien Allair, Albert.Beaulieu, Reginald.Baily, Freddy Gravel, Octavien Gosselin, Rosaire Julien, Clément.Ghislau Mining ou inconnu/or Unknown Ces terrains sont décrits dans un acte enregistré sous le No 153992.\u2014Those lands are described in a registered deed under No.153992.P.39, rg.1, canton-township Montauban.Borné-bound.N.chemin public Road, E.Clément Léveillée, S.Albert Allair, O./W.Ghislau Mining.P.39, rg.1, canton-township Montauban.Borné-bound.N.Albert Allair, E.chemin public Road.S.Patrick Bilodeau, O./W.Ghislau Mining.P.39, rg.1, canton-township Montauban.Borné-bound.N.Rosaire Gosselin, E.chemin public Road, S.Emilien Parent, O./W.Ghislau Mining.P.39, rg.1, canton-township Montauban.Borné-bound.N.Paul Garneau, E.& S.chemin public Road, O./W.munie.P.39, rg.1, canton-township Montauban.Borné-bound.N.Conseil, E.Etienne Caoutte, S.chemin public Road, O./W.Jos.C.Paquin.P.42, rg.1, canton-township Montauban.Borné-bound.N.chemin public Road, E.Pierre Audet, S.Gaston Audy; O./W.Camille Roy.P.39, rg.1, canton-township Montauban.Borné-bound.N.Rose-Aimé Gosselin, E.chemin public Road, S.Albert Allair, O./W.Ghisl.Mining.P.39, rg.1, canton-township Monbauban .P.37, rg.1, canton-township Montauban.P.38, rg.1, canton-township Montauban.P.39, rg.1, canton-township Montauban.P.40, rg.1, canton-township Montauban.P.41, rg.1, canton-township Montauban .1 75.15 $ 75.15 75.15 75.16 48.10 48.10 75.15 75.15 75.15 S 16.80 91.95 8.55 3.54 12.09 78.80 4.77 83.57 55.95 28.60 84.55 1.70 8.72 10.42 1-70 6.41 8.11 88.50 205.31 293.81 3.40 17.45 20.85 3.40 18.77 22.17 Municipalité de Pointe-aux-Trembles \u2014 Cadastre de Pointe-aux-Trembles Municipality of Pointe-aux-Trembles \u2014 Cadastre of Pointe-aux-Trembles Coderre, Rolland.Lot 345.Borné-bound.N.O./W.lots 481 & S 0 39 S ieoo < in mo 482, S.E.chemin-road.N.E.lots 346 & \">\u2022«»» 10.38 348, S.O./W.lot 344-1 x20 arp.A déduire- to withdraw parties vendues-parts solded : 2 de-of 75 x 75' à-at Charles Roy, 1 de-of 350 x 75' à-at Antoine Racette, à de-of 630 x 76' à-at Antoine Racette, 1 de-of 360 x 75' à-at Lea Placements De Gaudo Ltée. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.L 977 Corporation municipale de la paroisse de Notre-Dame de Portneuf \u2014 Cadastre de Notre-Dame de Portneuf Municipal corporation of the parish of Notre-Dame de Portneuf \u2014 Cadastre of Notre-Dame de Portneuf Taxes Taxes mun.scol.Propriétaire No du cadastre et description et int.et int.Total Owner Cadastre No.and description Mun.School taxes taxes and int.and int.Structallnc.2, P.217, 1 pt.borné-bound.N.O./W.che- $ 809.32 8 3,808.70 $4,618.02 min public road, Hector Hardy, Comm.scol.-sch.com., Jos.Julien, Mme-Mrs.Arsène Julien, N.E.chemin public road, we-wid.Arsène Julien, H.Paul Julien, Imelda Gauthier, S.E.P.218 & P.657, S.O./W.P.216.1 pt., borné-bound.N.chemin public road, E.H.P.Julien, O./W.Hector Hardy, S.Gauthier et-and Julien, et lot-and lot en premier lieu décrit-in first part described.Municipalité du village de Pont-Rouge \u2014 Cadastre de Sainte-Jeanne de Neuville Municipality of village of Pont-Rouge \u2014 Cadastre of Sainte-Jeanne de Neuville Thériault, Jean-Guy.65-1-53, rg.Ste-Jeanne.$ 154.32 $ 217.71 $ 372.03 Municipalité de Sainte-Jeanne de Pont-Rouge \u2014 Cadastre de Sainte-Jeanne de Neuville Municipality of Sainte-Jeanne de Pont-Rouge \u2014 Cadastre of Sainte-Jenne of Neuville Bolduc, Louis-Philippe.P.9.$ 3.70 $ 64.50 $ 68.20 Fiset.Robert.P.215 .4.52 63.71 68.23 Kelly, Mme-Mrs.André.P.204 .3.46 16.08 19.54 Robert LaceUe, Jean-Yves Savard, 145 P.45.45 316.78 362.23 Réjean St-Laurent.Richard, Raymond.215 P.3.44 48.97 62.41 \tMunicipalité du village de Saint-Alban \u2014 Municipality of the village of Saint-Alban ¦\tCadastre de SaintrAlban \u2014 Cadastre of SaintrAlban\t\t Arsenault, Georges.\t\t\t150.70 $\t185.40 \t\t\t\t \tMunicipalité de Saint-Basile, village sud -Municipality of SaintrBasile, village south\t- Cadastre de Saint-Basile \u2014 Cadastre of Saint-Basile\t\t \t.Pot 56-P.\t.$ 50.69 $\t110.67 $\t161.26 Succ.-est.Paul-André Page\t,.Lots P-286, P-286, 111 N.S.\t\t673.32\t808.62 \t\t\t\t \tMunicipalité de la paroisse de Saint-Basile Municipality of the parish of Saint-Basile -\t\u2014 Cadastre de Saint-Basile \u2014 Cadastre of Saint-Basile\t\t Succ.-est.Joseph Napoléon Bédard.P.334, rg.Ste-Anne.$ 11.60 $ 36.44 $ 48.04 Guillemette, Mme-Mrs.Jean-Louis.P.173, rg.St-Charlee.16.02 58.27 74.29 Lavallée, Mme-Mrs.Joseph____.'.P.173, rg.St-Charles.3.69 3.69 Doré, Albert.P.491.3.83 3.83 Municipalité de Sainte-Catherine \u2014 Cadastre de Sainte-Catherine Municipality of Sainte-Catherine \u2014 Cadastre of Sainte-Catherine Brière.Armand 346-14 $ 3.72 8 3.11 $ 6.83 978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, lOA' année, n° A Taxes Taxes mua.scol.Propriétaire No du cadastre et description et int.et int.Total Owner Cadastre No.and description Mun.School taxes taxes and int.and int.Mme-Mrs.Marguerite de la Durantaye P.163.Couture.Côté, André.P.48.Lacroix.Mme-Mrs.Elaine.P.48.Renaud, Joseph.P.173.$ 23.58 51.53 9.G8 162.10 $ 23.00 128.96 $ 46.58 51.53 9.68 291.06 Municipalité de Sainte-Christine \u2014 Cadastre de Notre-Dame de Portneuf et Saint-Raymond Municipality ol Sainte-Christine \u2014 Cadastre of Notre-Dame de Portneuf and Saint-Raymond Goudreau, Antoui.P.596, Seig.Perthuis.rg.1, cad.N.-Dame de-of Portneuf.Goudreau, Joseph.603 P., SPS, cad.de-of Notre-Dame de-of Portneuf, rg.1, Perthuis.Paquet, Henri.P.7, canton-township Colbert, cad.de-of St-Raymond.18.88 $ 30.22 12.68 31.79 6.60 31.76 49.10 44.47 38.36 Municipalité de la paroisse de Saint-Raymond \u2014 Cadastre de Saint-Raymond-Bois-Gosford Municipality of the parish of Saint-Raymond \u2014 Cadastre of Saint-Raymond-Bois-Gosford et-and Rocquemont & Colbert April, Armand.Barbeau, Armand.Beaunoyer, Gérard.Chevalier, Jean-Yves.Comtois, Gérard.Corcoran, Eddy.Dubord, Gilles.Duguay, Jean.Gauthier, Roméo.Durocher, John Patrick.Gingras, Georges-E.Gingras, Maurice.Giroux, Marc-Andrê.Langlais, John.Leclerc, Anselme.Magnan, Pierrette.Moisan, Léo-A.Paquet, Lucien.Richard.Cyrille.Verret, Jean-Claude- Whiton, Raymond.P.499, 3-B L.& P.539, P.540,2-B.L., cad.de-of St-Raymond.P.10, rg.1, Gosford, borné-bound.S.E.par- by G.Perron, N.E.par-by R.Demers, N.O./W.par-by F.Laberge, S.O./W.Lac Sept Iles, cad.St-Raymond.P.1E, & P.2A, rg.5, Gosford.P.33-4, rg.3, Rocquemont.P.33-6, A.B., 3, Rocquemont.P.7C, rg.6, Gosford & P.8A, Gosf.P.34-37, rg.3, Rocquemont.P.34-7, rg.3 et-and P.34-96, Roquemont.P.l,rg.3, Colbert.:.P.2-D-3-A-1.Colbert & P.6S5-6-B.L.P.34-82, rg.3.Rocquemont.P.34-24, rg.3, Rocquemont.P.34-68, rg.3, Rocquemont.P.576, 1 B.L.St-Raymond.P.10, rg.1, Gosford.P.34-56.rg.3, Rocquemont.P.588.1.B.L.St-Raymond.P.541, 6.B.L.St-Raymond.P.' 576, 1.B.L.St-Raymond.P.10, rg.1, Gosford.P.647,1-B.L.St-Raymond.S 103.53 S 248.28 S 351.80 23.57\t224.92\t248.49 37.90\t268.84\t306.74 1.70\t9.48\t11.18 \t43.57\t43.57 \t92.43\t92.43 7.17\t40.17\t47.34 \t15.07\t15.07 \t25.67\t25.67 21.84\t194.75\t216.59 1.10\t4.61\t5.71 1.10\t4.61\t5.71 1.10\t4.61\t5.71 8.17\t65.50\t73.67 \t14.22\t14.22 2.22\t7.61\t9.83 20.19\t104.72\t124.91 10.64\t120.07\t130.71 \t112.91\t112.91 6.35\t35.35\t41.70 \t22.14\t22.14 Municipalité de Rivière-à-Pierre \u2014 Cadastre de Canton Bois Municipality of Rivière-à-Pierre \u2014 Cadastre of Canton Bois Després, Pierre.Routhier, René.P.10, rg.2, Bois .P.19, rg.1, Bois.39.95 69.07 39.95 59.07 Municipalité de Saint-Léonard \u2014 Cadastre de Saint^Raymond Municipality of Saint-Léonard \u2014 Cadastre of Saint-Raymond Paquet, Henri Trudel, Noël.323 & 325 cone.1.P.164 & 132 conc.3 &2 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 979 Municipalité de Cap-Santé \u2014 Cadastre de Cap-Santé Municipality of Cap-Santé \u2014 Cadastre of Cap-Santé \t\tTaxes\tTaxes\t \t\tmun.\tscol.\t Propriétaire\tNo du cadastre et description\tet int.\tet int.\t \t\t\t\tTotal Owner\tCadastre No.and description\tMun.taxes and int.\tSchool taxes and int.\t Jean Desjardins & Benoit Barbeau.(Auberge de l'Étang) Gauthier.Wellie.154-1P, 154-2P, 154-3, 154-4, 154-5, 154-8P.154-7P, 154-9P, 154-12, 154-P, 154-6P.Tous ces lots ou parties de lots forment un tout et ce tout est borné comme suit:-All of those lots or parts of lots belong together and are bounded as said: O.-W.Egide Trépanier, S.CNR, E.Marcel Beaudry & ruis-seau-stream, N.chemin public road.P.393, borné-bond.N.chemin public road, S.chemin Chastenaye road, E.Eugène Langlais ou/or repr.$,353.27 $ 671.92 $2,025.19 1.85 19.46 21.31 Municipalité du village de Saint-Marc des Carrières \u2014 Cadastre de Saint-Alban Municipality of the village of Saint-Marc des Carrières \u2014 Cadastre of Saint-Alban Jos.O.Gauthier Ltée.P.10, P.11, P.15, (10-1, 11-1.11-2.11-3.$ 2,741.22 $18,019.27 $20,760.49 11-4).Municipalité de Notre-Dame des Anges \u2014 Cadastre de Notre-Dame des Anges Municipality of Notre-Dame des Anges\u2014 Cadastre of Notre-Dame des Anges Succ.-est.Dame Oscar Tremblay.2 terrains-landssur-onlot P.4, rg.5, S.O.-W.canton-township Montauban.Comme décrit dans acte-as described in deed No.93999 $ 176.76 $ 176.76 Municipalité de Saint-Rémi du Lac-aux-Sables \u2014 Cadastre de Saint-Ubald Municipality of Saint-Rémi du Lac-aux-Sables \u2014 Cadastre of Saint-Ubald United Montauban Mines Ltd.P.43, canton-township, Montauban, superf.area 68 arp.Borné-bound.S.E.No 42, N.E.bl.C.rg.2, N.O.-W.Anacon Lead Mines Ltd, S.O.-W.P.44.A distraire-to withdraw part, vendues-sold à-to A.Lessard, J.Délisle et-and T.Délisle.12.63 $ 92.00 $ 104.63 Donné à Cap-Santé, ce 17e jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44136-3-2-0 Vauquelin Frenette.Municipalité du comté d'Iberville Avis public est présentement donné par le soussigné, Bernard Larocque, secrétaire-trésorier de la corporation du comté d'Iberville, que les propriétés immobilières ci-après désignées seront vendues à l'enchère publique, au bureau dudit conseil, 55, 5e Avenue, en la.ville d'Iberville, JEUDI, le NEUVIÈME jour du mois de MARS 1972, à DIX heures du matin, à défaut de paiement des taxes municipales, scolaires ou autres redevances, avec les intérêts dus, tel que mentionnés ci-après, à moins que ces taxes, redevances, intérêts et frais ne soient acquittés avant la date de la vente à l'enchère.Given at Cap-Santé, this 17th day of January, 1972.Vauquelin Frenette, 44136-3-2-0 Secretary-Treasurer.Municipality of the county of Iberville Public notice is hereby given by the undersigned Bernard Larocque, Secretary-Treasurer of the Corporation of the county of Iberville, that the immovables hereinafter mentioned will be sold by public auction in the office of said council, in the Town of Iberville, 55, 5th Avenue, on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN\" o'clock in the forenoon, in default of the payment of municipal, school or other taxes plus accrued interests and costs, unless said taxes, interests and costs have been paid before the sale. 980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n\" 4 Paroisse de Saint-Sébastien \u2014 Parish of Saint Sebastien Propriétaire Owner Numéros officiels Official numbers Taxes munie.Munie, taxes Taxes scolaires School taxes Autres Others Total Succ.-Estate Josephine Methe.P.105.S 12.25 $ 37.£ $ 50.14 Paroisse de St-Georges \u2014 Parish of St.Georges Elias, Manuel-José.Briqueterie Richelieu.14 Sub.230.263 P6-264-265.$ 18.75 140.80 1.00 2.00 $ 19.75 142.80 Paroisse de Ste-Anne-de-Sabrevois \u2014 Parish of Ste Anne de Sabrevois Dupuis, Lionel.Guérin.Adrien.Racicot.Gilles.lllSub.2.:.$ 19.63 S 99.62 S 2.00 $121.16 134-158.3.46 17.35 1.00 21.80 P.138.18.46 87.95 2.00 108.40 Paroisse de Stt-Alexaiidre \u2014 Parish of St.Alexandre Mastrovito, Jean.Raymond.Jean-Pierre.Boyer, Marcel.Bisaillon, Mme Jeaji-YVes (Mrs.).Balthazar.Mme-Mrs.René.Bonneau, Roger.Forget.Albert.P.246.P.181.P.274 (S.20A-20D) .P.274 (S.71B).P.274 (S.93D).365-366-367.P.274 (S.23 a).$ 42,89 135.85 27.07 71.20 7.08 49.18 44.60 543.33 7.08 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 43.89 72.70 8.08 50.18 45.60 681.18 35.15 Ville d'Iberville \u2014 Town of Iberville Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (S.363).P.444 (S.361).P.444 (S.438).P.444 (S.369).P.444 (S.370).P.444 (S.377).P.444 (S.378).P.444 (S.379).P.444 (S.380).P.444 (S.381).P.444 (S.382).P.444 (S.383).P.444 (S.441).P.444 (S.402).P.444 (S.401).P.444 (S.400).P.444 (S.399).P.444 (S.398).P.444 (S.397).P.444 (S.396).P.444 (S.395).P.444 (S.394).P.444 (S.393).P.444 (S.371).P.444 (S.372).P.444 (S.373).P.444 (S.375).P.444 (S.376).P.444 (S.430).P.444-443 (S.386-387-386, 460).P.444-458, 459-3.445-412 à-to 416.P.444 (S.460).24.24\t$ 25.32\t$ 49.56 125.81\t25.32\t151.13 29.11\t30.39\t59.50 75.13\t16.88\t92.01 84.13\t20.26\t104.39 76.13\t16.88\t93.01 77.11\t16.88\t93.99 76.13\t16.88\t93.01 77.11\t16.88\t93.99 76.13\t16.88\t93.01 77.11\t16.88\t93.99 76.13\t16.88\t93.01 75.13\t16.88\t92.01 75.14\t16.88\t92.02 75.14\t16.88\t92.02 75.14\t16.88\t92.02 75.14\t16.88\t92.02 75.14\t16.88\t92.02 75.14\t16.88\t92.02 75.14\t16.88\t92.02 75.14\t16.88\t92.02 75.14\t16.88\t92.02 75.14\t16.88\t92.02 68.66\t20.26\t88.92 128.46 87.94\t40.52\t 71.78 86.56\t23.64 18.87\t95.42 105.43 90.99\t18.87\t100.86 8.09\t8.44\t16.53 573.77\t1.20\t1.20 \t84.79\t658.56 76.03\t3.78\t3.78 \t75.31\t151.34 \t1.20\t1.20 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 981 Propriétaire Numéros officiels Owner Official numbers Taxes Taxes munie.scolaires Autres Total Munie.School Others taxes taxes Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (S.443).Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (S.431).Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (,S.432).Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (S.433).Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (S.434).Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (S.419).Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (S.439).Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (S.406).Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (S.391).Iberville Relaty Ltd-Ltée.P.444 (S.389).Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (S.390).Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (S.459-458-445-444.Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (Hamel).Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (Bellerive).Iberville Really Ltd-Ltée.P.444-291 P.270.Iberville Realty Ltd-Ltée.P.444 (S.292).Syndic-Trustee Paul C.Perras.P.30.Succ.-Estate J.F.Thibault.305-P.306.Daneau.Conrad.P.386.Dugas.André.P.365.362.Dulude, Roger.30 s 103.Hamel.Bertrand.P.444 (S.156).Hamel, Laurent.P.11-8.Langlois, Guy.P.200.Pichette, Albert.383(s)-380(l).Tétreault, Gisèle P.115-115(40).Théberge, Lise.30-(172)-P.389.Bernard, Raoul.P.242.Chagnon, Gérard.245-128.Geoffroy.Georges.243 (79).Construction Pronto Constr.Inc.P.237.Souriche Inc.P.237- P.236.\tS 1.20\t\t$ 1.20 ! 9.68\t10.12\t\t19.80 9.68\t10.12\t\t19.80 12.91\t13.50\t\t26.41 12.91\t13.50\t\t26.41 8.09\t8.44\t\t16.53 125.88\t20.26\t\t146.14 164.49\t23.64\t\t188.13 80.01\t21.95\t\t101.96 140.98\t21.95\t\t1,62.93 86.59\t18.87\t\t105.46 \t2.16\t\t2.16 1,615.91\t521.77\t8 3.00\t2,140.68 95.63\t190.80\t\t286.43 85.58\t37.15\t\t72.73 24.24\t25.32\t\t49.56 1,801.73\t253.85\t0.50\t2,056.08 2,133.97\t2,369.95\t3.00\t4,506.92 113.23\t120.30\t2.00\t235.53 291.34\t340.95\t\t632.29 416.53\t488.62\t3.00\t908.15 232.64\t231.03\t3.00\t466.67 126.16\t254.32\t2.00\t382.48 83.51\t117.91\t2.50\t203.92 946.17\t883.81\t3.00\t1.832.98 202.60\t80.76\t2 50\t285.86 366.23\t107.74\t3.00\t476.97 435.57\t509.33\t3.00\t947.90 85.56\t84.09\t2.00\t171.65 78.80\t90.62\t2.00\t171.42 294.26\t1,665.39\t3.00\t1,962.65 3.35\t16.71\t1.00\t21.06 Paroisse de Saint-Athanase \u2014 Parish of St.Athanase Bombardier, Lucien.\t.SP-340.\tt 17\t64\tS 1.00\tS 18.64 \t231-34:231 (H de-of 33).\t2\t96\t1.00\t3.96 Bombardier, Alcide.\t.P.340.\t9\t88\t1.00\t10.38 \t.88-22; 88-14; 88-13.\t35\t34\t\t35.34 Gravel, Adrien.\t.S-21 -46.\t63\t31\t1.00\t64.31 \t,.SP-89.\t16\t55\t1.00\t17.55 \t.SP-73.\t81\t36\t1.00\t82.36 Le d'Iberville Motel Inc.\t.253- (1-7) (9-14).\t1,534\t63\t3.00\t1,637.63 \t,.P-412.\t54\t44\t1.00\t55.44 \t.SP-86.\t67\t10\t\t67.10 \t.SP-88.\t16\t30\t1.00\t17.30 Phaneuf, Eddy.\t.sP-88.\t103\t37\t1.00\t104.37 Tétreault, Roger.\t.SP-88.\t5\t59\t1.00\t6.69 \t.P-62(l).\t793\t85\t2.00\t795.85 \t.P-9.\t71\t.67\t2.00\t73.67 \t.235(3).\t308,\t68\t2.00\t310.68 Donné à Iberville, ce 14e jour du mois de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44143-3-2-o Bernard Larocque.Municipalité du comté d'Arthabaska Avis public est par le présent donné par le soussigné, Jean Moisan, avocat, secrétaire-trésorier de la municipalité du comté d'Arthabaska, que JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS, mil neuf cent soixante-douze, à DIX heures de l'avant-midi, heure normale de l'est, à la salle du conseil du comté d'Arthabaska, située au Given at Iberville, this 14th day of the month of January,1972.Bernard Larocque, 44143-3-2-0 Secretary-Treasurer.Municipality of the County of Arthabaska Public notice is hereby given by the undersigned, Jean Moisan, advocate, Secretary-Treasurer of the Municipality of the Countv of Arthabaska, that on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, one thousand nine hundred and seventy-two, at TEN o'clock in the forenoon.Eastern Standard Time, in 932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, h\" 4 bureau d'enregistrement, ville d'Arthabaska, chef-lieu du comté seront vendus à l'enchère publique, les immeubles ci-après désignés pour non paiement de taxes municipales, scolaires, frais et charges dus sur chacun de ces immeubles, à moins que ces taxes, frais et charges ne soient plus tôt payés et acquittés avec les frais encourus avant la vente, savoir: the County of Arthabaska Chambers, at the Registry Office of the Town of Arthabaska, County Seat the immoveables hereinafter described will be sold by public auction for non-payment of municipal and school taxes, costs and charges due on each of these immoveables, unless these taxes, costs and charges are paid and duly acquitted, with all costs incurred, before the seal, to wit.Municipalité de la paroisse de Saint-Rosaire \u2014 Municipality of the parish of Saint-Rosaire Noms\tLots\tRang\tCanton\tTaxes mun.\tTaxes scol.\tTotal Names\t\tRange\tTownship\tMun.taxes\tSchool taxes\t Houle, Félix.\t.375, P.370.\t\tBulstrode.\tS 82.48\t\tS 82.48 Beaudet, Philippe.\t.P.371.\t.7.\tBulstrode.\t34.09\t\t34.09 \t.P.406.\t.8.\tBulstrode.\t54.97\t\t54.97 \t.P.406.\t.8.\t\t70.76\t\t70.76 Allard, Henri.\t191, 192.\t4\tBulstrode.\t\t\t \tP.194, P.195, y2 o.26c.\t.4.\tStanfold.\t362.97\t\t362.97 Lamothe, Jean-Guy.\tP.n.24.\t6\tStan fold.\t55.68\t\t55.68 \t\t\t\t\t\t Municipalité du canton de Maddington \u2014 Municipality of the township of Maddington Labonté, Gaston.P.12b.Cont.du lie rg- 2.83 2.83 Municipalité de Saint-Albert de Warwick \u2014 Municipality of Saint-Albert of Warwick Guitard, Guy.1046, 1047.Bélanger, Georgette Mme.P.971.Gagnon .Richard.723, 724____ Lapierre, Paul.781-10.Leblanc, Emile.H n.e.699.Leclaire, Janet.P.971.Warwick.$ Warwick.Warwick.Warwick.Warwick.Warwick.19.89 $\t56.43 S\t76.32 \t2.10\t2.10 8.37\t16.56\t24.93 2.10\t22.24\t24.34 \t7.56\t7.56 0.80\t2.95\t3.75 Municipalité du canton de Warwick \u2014 Municipality of the township of Warwick\t\t\t Leblanc, Emile.596 et P.s.o.586.Warwick.\tS\t107.72 S\t107.72 Municipalité du canton de Tingwick \u2014 Municipality of the township of Tingwiok\t\t\t Dion, Henri-Louis.295, 296 et P.297.Tingwick.\t21.40 S 23.08 30.31 20.20\t14.76 S 59.09 165.92 82.10\t36.16 82.17 196.23 102.30 Municipalité de Chénier \u2014 Municipality of Chénier\t\t\t \t0.26 %\t0.41 S\t0.67 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 39, 1972, Vol lOl, No.L 983 Municipalité de Saint-Rémi de Tingwick \u2014 Municipality of Saint-Rémi of Tingwick Taxes Taxes Noms Rang Canton mun.scol.Lots Total Names Range Township Mun.School taxes taxes Chartier.Pierre.1156-25.EschenheiVer, Paul-André.916 et P.s.e.915.Ouelllette.Félix.P.1009.Tingwick.S Tingwick.Tingwick.3.61 S 7.49 106.05 4.35 11.10 106.05 4.35 Municipalité de Chester-Nord \u2014 Municipality of Chester-North Onyszuck, Georges.P.11.1.Par.St-Norbert.30.46 $ 30.46 Municipalité de la paroisse de Sainte-Elizabeth de Warwick Municipality of the parish of Sainte-Elizabeth of Warwick Dunn.Jacques.Beauchesne, Edmond.P.18.13____ Kingsey.627, P.628, P.629, Warwick.P.461.$ 1189 S 11.89 120.57 120.57 Municipalité de la paroisse de Sainte-Séraphine \u2014 Municipality of the parish of Sainte-Séraphine Huot, Robert.986, 992, 993, et P.S.E.987.Tessier, Moïse.P.n.o.18.11.Warwick.Kingsey.83.02 36.21 83.02 36.21 Municipalité de la paroisse de Sainte-Clothilde \u2014 Municipality of the parish of Sainte-Clothilde Forest, Gilles.P.19a.12- Carron, Dame Conrad.P.186.Grégoire, Gilles.P.17c.12- Kirouac, Claude.P.38.Paquin, Lucien.P.1107.Picard.René.P.19a.12- Gagnon, Henri-Paul.P.18c.11____ Turcotte, Réjean.P.17c.12- Guitard.Guy.1096, 1097, P.n.1098.P.n.o.1099 Simpson.Horton.Simpson.Horton.Horton.Simpson.Simpson.Simpson.Warwick.1\t40.74 S\t40.74 \t7.09\t7.09 \t1.29\t1.29 17.05\t26.81\t43.86 \t1.01\t1.01 4.40\t1.70\t6.10 18.45\t\t18.45 22.52\t\t22.52 \t44.05\t44.05 \tMunicipalité du village de Chesterville \u2014\t- Municipality of the village of Chesterville\t Bourassa, Gérard.Verville, Richard.\t.P.21.P.21.\tSt-Paul de Chester 3 134.89 St-Paul de Chester 146.34\t$ 134.89 146.34 \tMunicipalité de Chester-Est-\t\u2014 Municipality of Chester-East\t Boisvert, Arsène Binette, Jean-Marc.Gagnon, Renald.Mercier, Renald.187, 188.144, 145, 146, 147.118, 149, 150, 154, 155, 234, 235, P.148.310, 311, 312, 313.132, 279, 280.281, P.131 et P.133.Ste-Hélène de Chester.Ste-Hélène de Chester.Ste-Hélène de Chester.Ste-Hélène de Chester.17.89 425.35 26.02 70.24 17.89 425.35 26.05 70.24 984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i> année, n° A L'énumération abrégée des numéros cadastraux des immeubles a été autorisée par la Commission municipale de Québec, conformément aux dispositions de l'article 730, du Code Municipal.Donné sous mon seing à Arthabaska, ce dix-septième jour du mois de janvier, mil neuf cent soixante-douze.Le secrétaire-trésorier, 44167-3-2-o Me Jean Moisan.The abreviated enumeration of the cadastral numbers of the immoveables has been authorized by the Québec Municipal Commission, in conformity with the provisions of article 730 of the MunicipaJ Code.Given under my Seal at Arthabaska, this seventeenth day of the month of January, one thousand nine hundred and seventy-two.Me.Jean Moisan, 44167-3-2 Secretary-Treasurer.Municipalité du comté de Nicolet Avis public est par les présentes donné, par le soussigné André Villeneuve, secrétaire-trésorier du conseil municipal du comté de Nicolet, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l'enchère publique en la Salle publique au village de Béeancour, dans la ville de Béeancour, comté de Nicolet, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS, 1972, à DIX heures de l'avant-midi, pour les taxes municipales et scolaires dues aux différentes municipalités par les personnes dont les noms figurent en regard de chaque immeuble, à moins qu'elles n'aient été payées, y compris les frais, entre mes mains, avant la vente, savoir: Municipalité de la paroisse Ste-Marie de Blandford Propriétaire inconnu.\u2014 Des lots de terre portant les numéros P.865 (environ 10 arpents de terrain) et P.759 (environ 15 arpents de terrain) du cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Marie de Blandford.$6.22.Municipalité de Ste-Brigitte des Saults Ovila Cartier.\u2014 Un terrain mesurant 75 pieds par 180 pieds, portant le numéro P.40 du cadastre de la paroisse de Ste-Brigitte des Saults dans le rang La Fourche.$17.80.City Loan Finance Corp.\u2014 Une terre de soixante arpents, portant le numéro 163 du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Brigitte des Saults, dans le rang St-Patricc.$20.85.Georges Doire.\u2014 Un terrain mesurant 300 pieds par 290 pieds, portant le numéro P.80 du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Brigitte des Saults, rang St-Joseph.$200.54.C.Senneville.\u2014 Une terre de soixante arpents, portant le numéro 112 du cadastre de la paroisse de Ste-Brigitte des Saults, dans le rang St-Louis.$32.56.Yvon Proulx.\u2014 Un chalet, situé sur le lot P.40 du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Brigitte des Saults dans le rang La Fourche, terrain mesurant 75 pieds par 125 pieds.$56.27.Municipalité de Stc-Eulalie Jean-Baptiste Laliberté.\u2014 Une terre portant les numéros Yi S.O.du lot No 30 et 1/3 centre du lot No 30 du cadastre de Ste-Eulalie, dans le rang 11, ayant une superficie de 42 arpents.$125.66.Armando Perri.\u2014 Une terre ayant une superficie de 14 arpents, portant le numéro P.N.36 du cadastre de Ste-Eulalie dans le rang 12.$2.1.65.Municipality of the County of Nicolet Public notice is hereby given by the undersigned, André Villeneuve, Secretary-Treasurer of the Municipal Council of the County of Nicolet, that the immovables hereinafter designated will be sold by public auction in the Village of Béeancour, Public Auditorium, in the Town of Béeancour, County of Nicolet, THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for the municipal and school taxes due to various municipalities by the persons whose names appear opposite the description of each immovable, unless the said taxes plus the costs incurred, are paid before the date of the sale, to wit: Municipality of Parish of Ste.Marie de Blandford Owner unknown.\u2014 The 'lots of land bearing numbers P.865 (approximately 10 arpents of land) and P.759 (approximately 15 arpents of land) of the official cadastre for the Parish of Ste.Marie de Blandford, in the sixth range.$6.22.Municipality of Ste.Brigitte des Saults Ovila Cartier.\u2014 A tract of land measuring 75 feet by 180 feet, bearing number P.40 of the cadastre for the Parish of Ste.Brigitte des Saults in La Fourche Range.$17.80.City Loan Finance Corp.\u2014 A lot of land of sixty arpents, bearing number 163 of the official cadastre for the Parish of Ste.Brigitte des Saults.in St.Patrice Range.$20.85.Georges Doirc.\u2014 A lot of land measuring 300 feet by 290 feet, bearing number P.SO of the official cadastre for the Parish of Ste.Brigitte des Saults, in St.Joseph Range.$200.54.C.Senneville.\u2014 A lot of land of sixty arpents, bearing number 112 of the cadastre for the Parish of Ste.Brigitte des Saults, in St.Louis Range.$32.56.Yvon Proulx \u2014 A chalet, situated on lot P.40 of the official cadastre for the Parish of Ste.Brigitte des Saults, in La Fourche Range, the land measuring 75 feet by 125 feet.$56.27.Municipality of Ste.Eulalie Jean-Baptiste Laliberté.\u2014 A lot of land bearing numbers Yl S.W.of lot No.30 and 1/3 centre of lot No.30 of the cadastre of Ste.Eulalie, in range 11 containing 42 arpents.$125.66.Armando Perri.\u2014 A lot of land containing 14 arpents, bearing number P.N.36 of the cadastre of Ste.Eulalie in range 12.$21.65. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.I 985 Gianfranco Tucci.\u2014 Un terrain mesurant % d'arpent, portant le numéro P.N.E.36 du cadastre de Ste-Eulalie dans le rang 12.$15.15.C.S.Senneville.\u2014 Une terre de 34 arpents, portant le numéro 1/3 S.O.40 du cadastre de Ste-Eulalie, dans le rang 12.$14.65.Auclair Mastai.\u2014 Une terre de 69 arpents, portant le numéro P.E.238 du cadastre de Ste-Eulalie, dans le rang 4.$23.90.Léonard Camirand.\u2014 Une terre de 125 arpents, portant les numéros P.34 et 35 du cadastre de la paroisse de Ste-Eulalie dans le rang 12.$193.56.Michel Del Balso.\u2014 Une terre de 121 arpents portant le numéro P.S.O.37 du cadastre de Ste-Eulalie dans le rang 12.$224.81.Municipalité du village de St- Léonard D'Aston Rolland Therrien.\u2014 Une propriété portant le numéro 55-2 du cadastre officiel de la paroisse de St-Léonard D'Aston.$1,804.35.Bureau du conseil de comté de Nicolet, à Gentilly, ville de Béeancour, ce 14e jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44159-3-2-o Me André Villeneuve.Municipalité du comté de Champlain Avis public est donné à tous les contribuables et intéressés dans la municipalité du comté de Champlain, par la soussignée, secrétaire-trésorière, domiciliée en la paroisse de Ste-Geneviève de Batiscan, que les immeubles ci-dessous mentionnés seront vendus à l'enchère publique, en ladite paroisse de Ste-Geneviève, au lieu où le conseil de comté tient ses sessions, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS prochain (1972), à DIX heures de l'avant-midi, pour cotisations et taxes dues, à moins qu'elles ne soient payées avec les frais, avant la vente.Gianfranco Tucci/\u2014 A lot of land containing % °f an arpent, bearing number P.N.E.36 of the cadastre of Ste.Eulalir.in Range 12.$15.15.C.S.Senneville.\u2014 A lot of land of 34 arpents, bearing number 1/3 S.W.40 of the cadastre of Ste.Eulalie.in range 12.$14.65.Auclair Mastai.\u2014 A lot of land of 69 arpents, bearing number P.E.238 of the cadastre of Ste.Eulalie, in range 4.$23.90.Léonard Camirand.\u2014 A lot of land of 125 arpents, bearing numbers P.34 and 35 of the cadastre for the Parish of Ste.Eulalie, in range 12.$193.56.Michel Del Balso.\u2014 A lot of land of 121 arpents bearing number P.S.W.37 of the cadastre of Ste.Eulalie, in range 12.$224.81.Municipality of Village of St.Léonard d'Aston Rolland Therrien.\u2014 A property bearing number 55-2 of the official cadastre for the Parish of St.Léonard D'Aston.$1,804.35.Council Office of the County of Nicolet, at Gentilly, Town of Béeancour, this 14th day of January, 1972.Me.André Villeneuve, 44159-3-2 Secretary-Treasurer.Municipality of the County of Champlain Public notice is given to all taxpayers and interested parties of the municipality of the county of Champlain, by the undersigned, Secretary-Treasurer, residing in the parish of St.Geneviève de Batiscan, that the immoveables hereunder mentioned will be sold by public auction, in the said parish of St.Geneviève, in the county council chambers, on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, in default of payment of taxes, unless they are paid with costs before the sale.Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice \u2014 Municipality of the parish of Saint-Maurice \t\t\tTaxes\tTaxes\t Propriétaire\tDésignation\t\tmunie.\tscol.\t \t\tFabrique\t\t\tTotal Owner\tDesignation\t\tMunie, taxes\tSchool taxes\t Suce-Est.Eugène Vaillancourt.S 4.05 S 13.45 S 17.50 Terre à bois, Ptie 52 du cadastre de la paroisse de St- A wooded lot, part 52 of the cadastre of the Parish of St.Maurice.Maurice.Municipalité de la paroisse de N.-D.du Mont-Carmel \u2014 Municipality of the parish of N.-D.du Mont-Carmel Succ-Est, Conrad Buisson.$ 15.22 S 105.78 % 121.00 Le lot No 460 du cadastre de Mont-Carmel, sans bâtisse.Lot No.400 of the cadastre of Mont-Carmel, without buildings.Flavien Jourdain.4.52 18.74 23.26 Lot No P.360 du cadastre de Mont-Carmel, sans bâtisse.Lot No.Pt.360 of the cadastre of Mont-Carmel, without buildings. 986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10 A' année, n° A Municipalité de la paroisse de Sainte-Geneviève de Batiscan \u2014 Municipality of the parish of Sainte-Geneviève de Batiscan \t\t\tTaxes\tTaxea\t Propriétaire\tDésignation\t\tmunie.\tscol.\tTotal \t\tFabrique\t\tSchool\t Owner\tDesignation\t\tMunie.\t\t \t\t\ttaxes\ttaxes\t Julien Despins.S 21.24 S 70.21 t 91.45 Emplacement Partie du No 449 du cadastre de Ste-Gene- An emplacement, part of No.449 of the cadastre of St.viève, avec bâtisses dessus construites.Geneviève, with buildings constructed thereon.Mme-Mrs.Donat T.St-Arnaud.201.80 78.01 279.81 Emplacement Nos 105 et 109 du cadastre de Ste-Geneviève, Emplacement Nos.105 and 109 of the cadastre of St.avec bâtisses dessus construites.Geneviève, with buddings constructed thereon.Succ.-Est.Donat O.Trudel.11.00 35.13 46.13 Lot No 220 du cadastre de Ste-Geneviève.Lot No.220 of the cadastre of St.Geneviève.Municipalité de la paroisse de Saint-Louis de France \u2014 Municipality of the parish of Saint-Louis de France Antoine Asselin.S 195.03 8 11.94 » 206.97 Lot No P.76-1-2-3 du cadastre de St-Maurice.Lot No.Pt.76-1-2-3 of the cadastre of St.Maurice.André Boissonneault.65.05 65.05 Lot No P.475-A-B du cadastre de St-Maurice, mesurant Lot No.Pt.475-A-B of the cadastre of St.Maurice, meas-60 pieds anglais de largeur par 125 pieds anglais de profondeur.uring 50 English feet in width by 125 English feet in depth.Gilles Boucher.218.23 9.40 227.63 Lot No P.74 du cadastre de St-Maurice, mesurant 118 Lot No.Pt.74 of the cadastre of St.Maurice, measuring 118 pieds anglais de largeur par une profondeur approximative English feet in width by a depth of abour 275 English feet, de 275 pieds anglais.Emile Girard.246.51 27.64 274.15 Lot No P.74 du cadastre de St-Maurice, suivant titre Lot No.Pt.74 of the cadastre of St.Maurice according to a enregistré sous le No 210119.deed registered under No.210119.Jean Grenier.360.40 14.73 375.13 Lot No P.76 du cadastre de St-Maurice suivant contrat Lot No.Pt.76 of the cadastre of St.Maurice according to a enregistré sous le No 191805.deed registered under No.191805.Jean-Pierre Landry.6.14 3.65 9.79 Lot P.566 du cadastre de St-Maurice, suivant contrat Lot Pt.566 of the cadastre of St.Maurice according to a enregistré sous le No 193157.deed registered under No.193157.Wilfrid Lebel.60.87 162.38 223.25 Lot No P.487 du cadastre de St-Maurice, suivant contrat Lot No.Pt, 487 of the cadastre of St.Maurice according to a enregistré sous Ie No 213316, avec maison dessus construite.deed registered under No.213316.with a house constructed thereon.Edmond-Denis Marchand.142.87 15.59 158.46 Lot No P.74 du cadastre de St-Maurice, suivant contrat Lot No.Pt.74 of the cadastre of St.Maurice according to a enregistré sous le No 212200.deed registered under No.212200.Alphondor Savoie.4.28 3.68 7.96 Lot No P.74 du cadastre de St-Maurice, suivant contrat Lot No.Pt, 74 of the cadastre of St.Maurice, according to a enregistré sous No 211670.deed registered under No.211670.JulesSavoie.18.66 33.13 51.79 Lot No P.74 du cadastre de St-Maurice, avec chalet.Con- Lot No.Pt.74 of the cadastre of St.Maurice, with a chalet, trat enregistré sous No 197241 ; Deed registered under No.197241.Georges Héroux.260.05 16.59 276.64 Lot No P.76 du cadastre de St-Maurice, suivant contrat Lot No.Pt.76 of the cadastre of St.Maurice, according to a enregistré sous No 218074.deed registered under No.218074.J.-Roger Héroux et Jean-Guy Hénaire.16.56 426.87 443.43 Lot No P.584 du cadastre de St-Maurice, avec une grange Lot No.Pt.584 of the cadastre of St.Maurice, with a barn dessus construite, contrat enregistré sous No 212309.built thereon, deed registered under No.212309. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.L 987 Taxes Taxea Propriétaire Désignation munie.scoi.Fabrique Total Owner Designation Munie.School taxes taxes Aimé Launier.S 455.97 $ 142.81 S 598.78 Lot No P.475 du cadastre de St-Maurice.avec maison; Lot No.Pt.475 of the cadastre of St.Maurice, with a house; A distraire des parties vendues selon bons titres.save and to withdraw the parts sold by deeds.Maurice Launier.174.79 29.10 203.89 Lot No P.475 du cadastre de St-Maurice.suivant contrat Lot No.Pt.475 of the cadastre of St.Maurice, according enregistré sous le No 129647.Avec maison dessus construite.to a deed registered under No.129647.With a house built thereon.Municipalité de la paroisse de Saint-Tite \u2014 Municipality of the parish of Saint-Tite Mme-Mrs.Arthur Desaulniers et Suce-Est.Roméo Desaulniers ou Curatelle Publique.$ 59.27 S 236.76 S 296.03 Lot No 336 du cadastre de la paroisse de SUTite, sans Lot No.336 of the cadastre of the Parish of St.Tite, without bâtisse.a building.Municipalité scolaire de Normandie \u2014 School Municipality of Normandie Crète & Champoux Equipment.Une bâtisse sans terrain située sur le No 281 du Rang 2 sud-est Rivière St-Maurice, Seigneurie de Batiscan; Trefflé Chamberland ou inconnu.Un terrain faisant partie du No 328 du Rang 5 Rivière St-Maurice, Seigneurie de Batiscan, d'environ 100 pieds par 300 pieds.Théo Klaus.Lot No 556 du cadastre de la paroisse de St-Tite, à St-Sé-verin de Proulxville.S 177.13 $ 177.13 A building without land tenure situated on No.281 of Range 2 southeast of the St.Maurice River, Seigniory of Batiscan.' 79.68 79.68 A piece of land being part of No.328 of Range 5, St.Maurice River, Seigniory of Batiscan, measuring about 100 feet by 300 feet.1.80 63.75 65.55 Lot No.556 of the cadastre of the Parish of St.Tite, at St.Séverin de Proulxville.Municipalité scolaire de Grand'Mère \u2014 School Municipality of Grand'Mère Grand'Mère Crète Clément.Claude, Justin, et Yvanhoë.% 468.31 $ 96.89 S 565.20 No 140-62-1 du cadastre de Ste-Flore.No.140-62-1 of the cadastre of Ste-Flore.Garceau, Alfred.17.16 36.77 53.93 Lot No Ptie 5 du cadastre de Ste-Flore de 100 pieds de Lot No.Pt.5 of the cadastre of St.Flore, 100 feet in width largeur par 200 pieds de profondeur, mesure anglaise.by 200 feet in depth, English measure.Sainte-Flore Déziel.Ernest.!.Lot No P.230 du cadastre de Ste-Flore, avec bâtisse dessus construite, de 51' x 117'.Gignac, Maurice.Lot No P.181-1 du cadastre de Ste-Flore (partie de la moitié nord-est du lot P.181), contenant un arpent et demi de front sur la profondeur d'environ cinq arpents.Gignac, Maurice.Partie du No 224 du cadastre de Ste-Flore louée par bail, mesurant 100' de largeur par 50' de profondeur, avec maison y érigée, à distraire la partie vendue au Ministère de la Voirie.S 137.97 S 888.38 S 1,026.35 Lot No.Pt.230 of the cadastre of St.Flore, with a building constructed thereon, 51' x 117'.972.83 972.83 Lot No.Pt.181-1 of the cadastre of St.Flore (part of the northeast half of lot Pt.181) measuring one and one-half arpents in front by a depth of about five arpents.160.09 54.87 214.96 Part of No.224 of the cadastre of St.Flore rented by lease, measuring 100' in width by 50' in depth, with a house erected thereon, save and to withdraw the part sold to the Department of Roads. OSS GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101' année, n\" L Taxes Taxes Propriétaire Désignation munie.scol.Fabrique Total Owner Designation Munie.School taxes taxes Bertrand Lavergne.1.Un terrain situé au Lac des Piles, faisant partie du No 436 du cadastre de Ste-Flore, borné au sud-ouest partie par le chemin public et partie par P.436 appartenant à C.Gélinas ou représentants, au nord partie par P.436 de Camille Gélinas et partie par le lac des Piles, au nord-est par le résidu dudit lot 436 de S.Aboud, et au sud-est par le chemin privé.2.Terrain au Lac des Piles, Ptie 436 du cadastre de Ste-Flore; borné à l'ouest par le nouveau chemin, au nord par le résidu de 436; au nord-est par les terres du rang St-Olivier, au sud-ouest par le No 437.3.Terrain au Lac des Piles.P.436 du cadastre de Ste-Flore.mesurant, mesure anglaise, 35' de largeur sur la profondeur de 50', avec bâtisse; .$ 477.71 $ 1.198.79 S 1,676.50 1.A piece of land situated at Lac des Piles, being part of No.436 of the cadastre of St.Flore, bounded partly on the southwest by the public road and partly by Pt.436 belonging to C.Gélinas or representatives, on the north partly by Pt.436 belonging to Camille Gélinas and partly by Lac des Piles, on the northeast by the remainder of said lot 436 belonging to S.Aboud, and on the southeast by the private road.2.A piece of land at Lac des Piles, part 436 of the cadastre of St.Flore, bounded on the west by the new road, on the north by the remainder of 436, on the northeast by the lands on St.Olivier Range, on the southwest by N.437.3.A piece of land at Lac des Piles, part 436 of the cadastre of St.Flore, measuring 35' in width by a depth of 50', English measure, with a building.Veillette, Robert.141-257 du cadastre de Ste-Flore.78.71 141-257 of the cadastre of St.Flore.184.84 263.55 Saint-Théophile du Lac Cechini, David (inconnu-unknown).993 cadastre de N.-D.du Mont-Carmel.Champagne, J.Noël.Terrain faisant partie du lot No 15 du Rang neuf (Rg.9) du Canton Radnor, dans la paroisse de St-Théophile du Lac, mesurant 75 pieds de largeur sur une profondeur de cinquante pieds, mesure anglaise, plus ou moins.Courcy, Antonio.Partie du lot 19 du Rang 7 Radnor, mesurant 50' de largeur sur la profondeur de 100'.Contrat enregistré à Shawinigan sous No 16262.S 3.91 S 13.19 S 17.10 993 of the cadastre of Notre-Dame du Mont-Carmel.5.57 67.78 73.35 A piece of land being part of lot No.15 of range nine (R.9) of the Township of Radnor, in the Parish of St.Théophile du Lac, measuring 75 feet in width by a depth of fifty feet, English measure, more or less.93.90 93.90 Part of lot 19 of Range 7, Radnor, measuring 50' in width by a depth of 100'.Deed registered in Shawinigan under No.16262.Ferland, Mme-Mrs.Bruno (Anna Lafrenière).16.98 132.79 149.77 Le lot au complet 11 No 5 Rang 8 Canton Radnor, sans All of lot 11, No.5, Range 8.Township of Radnor, without bâtisse, Enregistrement No 5827.buildings.Registration No.5827.Lagacé, Paul-Emile.27.65 27.65 Lot No 849 cadastre de N.D.du Mont-Carmel; Lot No.849 of the cadastre of Notre-Dame du Mont-Car- mel.Mongrain, Prudent.4.38 15.88 20.26 Terrain dans le rang St-Mathieu, Partie du No 992 du ca- A piece of land on the St.Mathieu Range, part of No.992 dastre de N.D.du Mont-Carmel, contrat enregistré sous le No of the cadastre of Notre-Dame du Mont-Carmel deed re-197880.gistered under No.197880.Périgny, J.-P.17.80 71.49 89.29 Terrain faisant partie du No 17 du Rang 7 du cadastre A piece of land being part of No.17 of Range 7 of the Canton Radnor, dans la paroisse de St-Théophile du Lac, cadastre of the Township of Radnor, in the Parish of St.avec bâtisse et tout ce qui se trouve sur les lieux.Enregis- Théophile du Lac, with a building and any object subsisting trement No 157411.thereon.Registration No.157411.St-Jean Roland.4.59 13.19 ' 17.78 Terrain dans le Rang St-Mathieu, P.992 du cadastre de A piece of land in the St.Mathieu Range, Pt.992 of the N.D.du Mont-Carmel, avec bâtisse, mesurant 76' de largeur cadastre of Notre-Dame du Mont-Carmel, with a buildiniz sur la profondeur de 100'.measuring 75' in width by a depth of 100'.St-Jean Ronald.4.90 19.90 24.72 Terrain Partie du No 993 du cadastre de N.D.du Mont- A piece of land being part of No.993 of the cadastre of Carmel, mesurant 100' de largeur sur une profondeur de 120' Notre-Dame du Mont-Carmel, measuring 100' in width by a sans bâtisse.depth of 120', without buildings. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.A 9S9 Grandes Piles Taxes Taxes Propriétaire Désignation munie.scol.Fabrique Total Owner Designation Munie.School taxes taxes Désilets, Rodolphe.$ 3.12 S 7.69 $ 10.81 Partie No 205 dans le Rang 2 du Canton Radnor; bornée Part No.205 on Range 2 of the Township of Radnor, au nord par Mme Gaétane Lachance, au sud par Mme Alex.bounded on the north by Mrs.Gaétane Lachance, on the Jourdain, à l'est par la route 19, à l'ouest par la 4e Avenue.south by Mrs.Alex Jourdain, on the east by Highway 19, on the west by 4th Avenue.Municipalité de Saint-Théophile du Lac \u2014 Municipality of Saint-Théophile du Lac Bélanger, Jean-Paul.Ptie 992 du cadastre de N.D.du MonUCarmel, de 375' de largeur sur la profondeur de 140', voir contrat enregistré sous No 13,826, avec chalet.Marchand, J.-A.Succession-Estate .Partie du lot numéro onze du rang huit subdivision du lot 25 (25-P 11 Rang 8) du cadastre du Canton Radnor; borné en front par le lac, en profondeur par le chemin; d'un côté par le terrain de Emery Soucy, et d'autre côté par celui de Ovila Bellemare ou leurs représentants.* 21.57 $ 43.43 S 65.00 Part 992 of the cadastre of Notre-Dame-du-Mont-Carmel.375' in width by a depth of 140', under the deed registered under No.13,826, with a chalet.48.46 178.32 ' 226.78 Part of lot number eleven of range eight, subdivision of lot 25 (25 Pt.11, Range 8) of the cadastre of the Township of Radnor, bounded in front by the lake, in depth by the road, on one side by the land of Emery Soucy and on the other side by that of Ovila Bellemare or representatives.Marchand, J.-A.Succession.Terrain connu et désigné sous le No 8 de la subdivision officielle du No 11 du Rang 8, subdivision du lot 25, du cadastre du Canton Radnor, avec bâtisses; borné en front par le chemin, en profondeur et d'un côté par le terrain de Dieudonné Daniel, et d'autre côté par celui de Camille Bellemare ou leurs représentants.Mayer.Réal.Ptie 849 du cadastre de N.D.du Mont-Carmel, de 170' x 100', suivant contrat enregistré sous le No 4033.Trudel, & Sansfacon.Partie No 1022 du cadastre de N.D.du Mont-Carmel; terrain de 150' de largeur par 200' de profondeur; borné en front par le chemin public, en arrière par Dame Alphonse Desaulniers, d'un côté par le terrain de la Commission scolaire; de l'autre côté, par un terrain appartenant à Geo.Magnan et par un autre terrain appartenant à E.Courchesne.Racette, Marcel.Seulement une bâtisse située sur l'Ile portant le No P.1044 du cadastre de N.D.du Mont-Carmel.10.48 39.62 50.10 A piece of land known and described under No.8 of the official subdivision of No.11 of Range 8, subdivision of lot 25 of the cadastre of the Township of Radnor, with buildings, bounded in front by the road, in depth and on one side by the land of Dieudonné Daniel and on the other side by that of Camille Bellemare or representatives.8.03 10.09 18.12 Part 849 of the cadastre of Notre-Dame du Mont-Carmel, 170' x 100', according to a deed registered under No.4033.45.40 154.29 199.69 Part No.1022 of the cadastre of Notre-Dame-du-Mont-Car-mel, a piece of land of 150' in width by 200' in depth, bounded in front by the public road, in the rear by Mrs.Alphonse Desaulniers.on one side by the land of the School Board, on the other side by a piece of land belonging to Geo.Magnan and by another piece of land belonging to E, Courchesne.19.59 30.00 49.59 A single building situated on the Island numbered Pt.1044 of the cadastre of Notre-Dame-du-Mont-Carmel.Commission Scolaire du Haut St-Maurice \u2014 Haut St-Maurice School Board Secteur Parent \u2014 Parent Sector P.T.Appieby (Succession).8 7.02 S 9.85 $ 16.87 Bloc B-B 173, Canton Lamy, cadastre de Parent.Block B-B 173, Township of Lamy, cadastre of Parent.G.E.Arseneault.169.38 169.38 Bloc K-K 54, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block K-K 54, Township of Lamy (Parent), with buildings.Lionel Beaudoin.243.90 176.79 420.69 Bloc B-B 11-2, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block B-B 11-2, Township of Lamy (Parent), with buildings.Paul-Emile Beaudoin.118.37 226.90 345.27 Bloc E-E 20, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block E-E 20.Township of Lamy (Parent), with buildings. 990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10 A' année, n° A Propriétaire Owner Désignation Designation Fabrique Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total John Boucher.S 29.66 S 66.79 8, 96.45 Bloc F Partie, Canton Lamy, (Parent), avec bâtisses.Block F Part, Township of Lamy (Parent), with buildings.Joe.Brown.10.00 19.16 29.16 Rang-3-22-A, Canton Lamy (Parent).Range 3-22-A, Township of Lamy (Parent).William Burgess (Suce.).67.50 126.39 193.89 Bloc K-K 130, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block K-K 130, Township of Lamy (Parent), with buildings.Edouard Castonguay.45.00 71.28 116.28 Bloc B-B 177.Canton Lamy (Parent).Block B-B 177, Township of Lamy (Parent).Jules Chouinard.230.47 230.47 Bloc B-B 139, Canton Lamy (Parent).Block B-B 139, Township of Lamy (Parent).Pamphile Chouinard.306.96 469.47 776.43 Bloc B-B 122, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block B-B 122, Township of Lamy (Parent), with buildings.Paul-Emile Cloutier.20.33 11.17 31.60 Bloc K-K 269, Canton Lamy (Parent).Block K-K 269, Township of Lamy (Parent).Couvrette & Casoni.479.93 981.16 1,461.09 Bloc Bl-11, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block Bl-11, Township of Lamy (Parent), with buildings.Claude Couvrette.67.30 36.93 104.23 Bloc E-E 138, Canton Lamy (Parent).Block E-E 138, Township of Lamy (Parent).Yves Couvrette.257.95 165.72 423.67 Bloc B-B 28, Canton Lamy (Parent).Block B-B 28.Township of Lamy (Parent).Gérard Dallaire.199.83 86.35 286.18 Bloc B-B 86, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block B-B 86, Township of Lamy (Parent), with buildings.Mme Pascal Dallaire.71.90 60.83 132.73 Bloc B-B 87!^, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block B-B 87 Township of Lamy (Parent), with buildings.Oscar Déry.25.41 192.75 218.16 Bloc.3-6, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block 3-6, Township of Lamy (Parent), with buildings.Oscar Duplessis.129.11 23.81 152.92 Bloc 1-19, Canton Lamy (Parent).Block 1-19, Township of Lamy (Parent).Donald Durand.92.31 114.77 207.08 Bloc B-B 97.Canton Lamy (Parent).Block B-B 97, Township of Lamy (Parent).Mme Marguerite Durand.228.83 178.74 407.57 Bloc F-Partie, Canton Lamy (Parent), borné d'un bout Block F-Part of the Township of Lamy (Parent), bounded par une rue projetée, à l'autre bout par le terrain du C.N.at one end by a planned street, at the other end by the land of entre M.Martel ou Casoni d'un côté et M.Lamothe de l'autre, the C.N.between Mr.Martel or Casoni on one side and Mr.avec bâtisses.Lamothe on the other, with buildings.J.Léon Fournier.177.37 177.37 Bloc K-K 121, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block K-K 121.Township of Lamy (Parent), with buildings.Isidore Garneau.68.60 635.23 703.73 Bloc G-G2, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block G-G2.Township of Lamy (Parent), with buildings.Gilles Geoffroy.500.13 212.08 712.21 Bloc K-K 100, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block K-K 100.Township of Lamy (Parent), with buddings.Albert Gendron.230.80 245.88 470.68 Bloc K-K 155.Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block K-K 155, Township of Lamy (Parent), with buildings.Marcel Geoffroy.880.38 880.38 Bloc E-E- 58.Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block E-E 58, Township of Lamy (Parent), with buildings QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 39, 1973, Vol.10k, No.4 991 .Taxes Taxes Propriétaire Désignation munie.scol.Fabrique Total Owner Designation Munie.School taxes taxes Marcel Geoffroy.$ 55.77 8 65.77 Bloc E-E 57, Canton Lamy (Parent).Block E-E 57, Township of Lamy (Parent).Roland Imbeault, décédé.$ 13.07 16.41 29.48 Rang 3-19.Range 3-19.Jos.Jean.98.43 98.43 Bloc G-G 4, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block G-G 4, Township of Lamy (Parent), with buildings.Gérard Juneau, décédé.68.80 34.01 92.81 Bloc K-K 1, Canton Lamy (Parent).Block K-K 1, Township of Lamy (Parent).Succ.Kirouac.10.00 12.94 22.94 Bloc H, Canton Lamy (Parent).Block H, Township of Lamy (Parent).Antonio Lachance.114.18 233.99 348.17 Bloc B-B 104, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block B-B 104, Township of Lamy (Parent), with buildings.Gérard Lacroix.265.71 265.71 Bloc 3-17, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block 3-17, Township of Lamy (Parent), with buildings.Raymond Landry.113.05 253.66 366.70 Bloc E-E 72, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block E-E 72, Township of Lamy (Parent), with buildings.François Ledantec.92.65 195.41 287.96 Bloc K-K 139, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block K-K 139, Township of Lamy (Parent), with buildings.RenéLevac.247.20 268.23 515.43 Bloc S-92-3, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block 8-92-3, Township of Lamy (Parent), with buildings.JohnMcNulty.103.13 103.13 Bloc F-Ptie, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block F-Part, Township of Lamy (Parent), with buildings.Cyrice Michaud.32.41 107.23 139.64 Bloc F-Ptie.Canton Lamy (Parent), borné en front par une Block F-Part of the Township of L3my (Parent), bounded rue projetée, profondeur Lac Mauser, d'un côté par Camille in front by a planned Street, in depth of Mauser Lake, on one Pakuot, et de l'autre par le Bloc E 171, avec bâtisses.side by Camille Paknot and on the other side by Block-E 171, with buildings.Gilles Michaud.,.'.157.72 157.72 Bloc E-E 21, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block E-E 21, Township of Lamy (Parent), with buildings.JackMidlidge.154.27 154.27 Bloc G-G 1, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block G-G 1, Township of Lamy (Parent), with buildings.Raymond Moisan.14.51 14.51 Bloc B-B 16, Canton Lamy (Parent).Block B-B 16, Township of Lamy (Parent).H.S.Northrup, décédé.41.60 27.60 69.20 Bloc B-B 42, Canton Lamy (Parent).Block B-B 42, Township of Lamy (Parent).Aimé Pageau, décédé.29.50 18.88 48.38 Bloc B-B 68, Canton Lamy (Parent).Block B-B 68, Township of Lamy (Parent).Jean-Marc Parent.67.12 107.76 174.87 Bloc E-E 116, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block E-E 116, Township of Lamy (Parent), with buildings.Yves Parent.192.33 188.06 380.39 Bloc F-Partie, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block F-Part.Township of Lamy (Parent), with buildings.Mme Zenon Pineault.55.563 656.63 Bloc 3 et 4, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block 3 and 4, Township of Lamy (Parent), with buildings.Léo Poulin.20.40 75.12 95.62 Bloc B-B 89, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Block B-B 89.Township of Lamy (Parent), with buildings. 992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n' 4 Taxes Taxes Propriétaire Désignation munie.scol.Fabrique Total Owner Designation Munie.School taxes taxes Louis Rivest, décédé.Bloc K-K 95, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Roch Rochette.Bloc J-J2 Ptie, Canton Lamy (Parent), avec bâtis Mme Edmond Simard.Bloc 2-5, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Germain Simard.Bloc B-B 118.Canton Lamy (Parent).Arthur St-Hilaire.Bloc 8-4, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses, Arthur St-Hilaire.Bloc B-B 151, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Daniel St-Hilaire.Bloc B-B 31, Canton Lamy (Parent).Daniel St-Hilaire.Bloc B-B 18, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Jean-Yves St-Hilaire.Bloc K-K 21, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Lauréat St-Hilaire.Bloc 8-5, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Charles E.St-Pierre, décédé.Bloc B-B 154, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Suce.J.A.Turmel.Bloc G-G 1, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Welly Thibault.Bloc K-K 122, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.Paul André Trudeau.Bloc E-E 8, Canton Lamy (Parent), avec bâtisses.James Young, décédé.Bloc K-K 176.Canton Lamy (Parent).8 46.90 8 51.42 8 98.32 Block K-K 95, Township of Lamy (Parent), with buildings- 216.61 147.87 364.38 Block J-J2, Part, Township of Lamy (Parent), with buildings.66.16 118.43 184.69 Block 2-5.Township of Lamy (Parent), with buildings.10.75 14.50 Block D-B I4S.Township of Lamy (Parent).25.25 .1.099.72 163.67 1,263.38 Block 8-4.Township of Lamy (Parent), with buildings.788.66 788.66 Block B-B 151, Township of Lamy (Parent), with buildings.12.32 12.32 Block B-B 31, Township of Lamy (Parent).158.76 168.76 Block B-B 18, Township of Lamy (Parent), with buildings.37.95 223.64 261.59 Block K-K 21, Township of Lamy (Parent), with buildings.88.70 142.89 231.69 Block 8-5, Township of Lamy (Parent), with buildings.136.03 75.37 211.40 Block B-B 154.Township of Lamy (Parent), with buildings.1,151.90 576.15 1,728.05 Block G-G 1, Township of Lamy (Parent), with buildings.247.04 144.19 391.23 Block K-K 122, Township of Lamy (Parent), with buildings.74.16 133.80 207.90 Block E-E 8, Township of Lamy (Parent), with buildings.18.87 Block K-K 170, Township of Lamy (Parent).IS S7 Secteur 4 Milles \u2014 4 Miles 8cctor Adrien Baril.37-7-34, Rang 1.Canton Mailhot, avec bâtisses.Denis Boudreau.50-81-51-53, Canton Mailhot.Aimé Doucet.39-6-1, ptie Rang 1, Canton Mailhot, avec bâtisses.Gérard Guillemette.50-98, Rang 1, Canton Mailhot.Mme-Mrs.Florence Lambert.50-80, 61-52, Canton Mailhot.8 54.58 $ 64.58 37-7-34.Range 1.Township of Mailhot, with buildings.11.47 11.47 50-81-51-53, Township of Mailhot.$ 266.35 396.89 663.24 39-6-1, Part of Range 1, Township of Mailhot, with buildings.2.48 2.48 50-98, Range 1, Township of Mailhot.15.27 15.27 50-80, 51-52.Township of Mailhot. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.I 993 Taxes Taxes Propriétaire Désignation munie.scoi.Fabrique Total Owner Designation Munie.School taxes taxes Mme-Mrs.Noëlle B.Larouche.39-5-32-6-10, Canton Mailhot, avec bâtisses.Raoul Létourneau.Rang 221, Canton Mailhot, avec bâtisses.Bruno Morissette.39-7-6-6-24, Canton Mailhot, avec bâtisses.Roméo Néron.39-7-26, Rang 1, Canton Mailhot.avec bâtisses.Roméo Noël.42-5-19, Rang 1, Canton Mailhot, avec bâtisses.François Rouette.Rang 221, Canton Mailhot, avec bâtisses.Mme-Mrs.Jean-Baptiste Tremblay.38-5-3, Ptie, Rang 1, Canton Mailhot.Jean-Paul Tremblay.38-7-29, Rang 1, Canton Mailhot.$ 205.52 $ 205.52 39-5-32-6-10, Township of Mailhot, with buildings.175.70 176.70 Range 221, Township of Mailhot, with buildings.766.61 766.61 39-7-6-6-24, Township of Mailhot, with buildings.76.63 700.39 777.02 39-7-26, Range 1, Township of Mailhot, with buildings.91.00 170.58 261.58 42-5-19, Range 1, Township of Mailhot, with buildings.529.84 529.84 Range 221, Township of Mailhot, with buildings.21.19 56.56 77.76 38-5-3, Part of Range 1, Township of Mailhot.97.82 58.03 155.58 38-7-29, Range 1, Township of Mailhot.Secteur La Croche \u2014 La Croche Sector Victor Desserres.$ 38.93 $ 98.36 $137.29 17 Ptie ouest; Canton Langelier, borné au front par le che- 17, west part of the Township of Langelier, bounded in min public, en profondeur par Shawinigan W.& P.Corp.front by the public road, in depth by Shawinigan W.& P.côté nord par le No 18, côté sud par le No 16, avec bâtisses.Corp., on the north side by No.18, on the south side by No.16, with buildings.Jean Gaudreault.30.49 30.49 25, ptie Est, Canton Langelier.25, east part of the Township of Langelier.Inconnu-Unknown.35.92 35.92 46, Ptie Canton Langelier.46, part of the Township of Langelier.Reginald Jean.14.83 169.29 174.12 34 Ptie est, Canton Langelier, borné au nord par le 34 Ptie, 34, east part of the Township of Langelier, bounded on the à l'est par le chemin public, au sud par le résidu de 34, à l'ouest north by part 34, on the east by the public road, on the south par la rivière La Croche, avec bâtisses.by the remainder of 34, on the west by La Croche River, with buildings.Jean-Guy Létourneau.3.23 58.87 62.10 54, Pties Est, Canton Langelier, avec bâtisses.54, east part of the Township of Langelier, with buildings.Jean-Guy Paquet.48.07 100.31 148.38 13 Ptie ouest, Canton Langelier, borné au sud-est par le lac, 13, west part of the Township of Langelier, bounded on the au nord-ouest par M.Grenon, au sud-ouest par le lot 13, et southeast by the lake, on the northwest by Mr.Grenon, on the au sud-est par le No 13, avec bâtisses.southwest by lot 13 and on the southeast by No.13, with buddings.Succ.-Est.P.Bellemare.4.58 36.86 41.44 9 Ptie ouest, Canton Langelier, borné au nord par le résidu 9, west part of the Township of Langelier, bounded on the du No 9, à l'ouest par le chemin public, et à l'est et au sud par north by the remainder of No.9, on the west by the public le No 9 road and on the east and south by No.9.Succ.-Est.Ernest Trudel.3.36 18.25 21.61 10, Ptie Rang 2, Ouest Canton Langelier.10, part of Range 2, west of the Township of Langelier. 994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10h' année, n\" L Secteur La Bostonnais \u2014 La Bostonnais Sector Taxes Taxes Propriétaire Désignation munie.scol.Fabrique , Total Owner Designation Munie.School taxes taxes Lionel Baillargeon.* 177.86 S 177.86 45, Ptie Rang Sud-Est, Canton Bourgeois, avec bâtisses.45, part of the southeast range of the Township of Bourgeois, with buildings.Yvon Baillargeon.197.24 197.24 35-34, Rang Sud-Est, Canton Bourgeois, avec bâtisses.34-35, southeast range of the Township of Bourgeois, with buildings.Yvon Baillargeon.19.08 19.08 46, Ptie Rang Nord-Ouest, Canton Bourgeois.46, part of the northwest range of the Township of Bourgeois.Bertrand Levesque.657.57 657.57 38-39, Pties Rang Nord-Ouest, Canton Bourgeois, avec bâ- 38-39, part of the northwest range of the Township of tisses.Bourgeois, with buildings.Maurice Smith.99.79 99.79 30, Rang Sud-Est, Canton Bourgeois, avec bâtisses.30, southeast range of the Township of Bourgeois, with buildings.Secteur Carignan \u2014 Carignan Sector Gabriel Bisson.$ 92.75 S 92.75 219-3, Canton Pothier, avec bâtisses.219-3, Township of Pothier, with buildings.Mme-Mrs.André Bissonnette.106.45 106.45 Rang 1-35, Canton Boucher, avec bâtisses.Range 1-35, Township of Boucher, with buiTdings, Léonidas Bouchard.12.04 12.04 Rang 1 5, Ptie Canton Boucher.Range 1 6 part of the Township of Boucher.Denis Boudreau.35.78 35.78 51-65, Rang 1, Canton Mailhot.51-65, Range 1, Township of Mailhot.Rémi Bousquet.' 280.81 280.81 H-5 Ptie, Canton Mailhot, borné à l'ouest par le chemin de H-5, part of the Township of Mailhot, bounded on the fer, au nord-ouest par l'ancien chemin, au sud-ouest par M.west by the railroad, on the northwest by the former road, on Turenne, au sud-est par le lac, au nord-est par le vendeur, the southwest by Mr.Turenne, southeast by the lake and avec bâtisses.northeast by the vendor, with buildings.Henry B.Cashing.28.58 28.58 16, Ptie Canton Carignan.16, part of the Township of Carignan.Artie Chandonnet.258.39 258.39 7, Rang 1, Canton Boucher, avec bâtisses.7, Range 1, Township of Boucher, with buildings.Roger Chartrand.23.23 23.23 22, Ptie Rang 1, Canton Carignan.22, part of Range 1, Township of Carignan.Osias Corbeil.6.40 6.40 65D-5, Rang 1, Canton Mailhot.65D-6, Range 1, Township of Mailhot.André Crête.104.84 104.84 48, Ptie Rang Ouest, Seigneurie de Batiscan, avec bâtisses.48, part of the west range, Seigniory of Batiscan, with buildings.Mme-Mrs.Arlène Dalbeck.18.62 18.62 16, Ptie Canton Carignan.15, part of the Township of Carignan.Raymond Desaulniers.95.88 95.88 32, Ptie Rang 1, Canton Carignan, avec bâtisses.32, part of Range 1, Township of Carignan, with buildings QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.L 995 Taxes Taxes Propriétaire Désignation munie.scol.Fabrique ToUl Owner Designation Munie.School taxes taxes Antonio Doucet.( 21.87 8 21.87 61-46, Rang 1, Canton Mailhot.51-46, Range 1, Township of Mailhot.Raymond Filion.112.21 112.21 16 Ptie, Canton Carignan, borné au front par le lac Chat, 15, part of the Township of Carignan, bounded on front by à l'arrière par Germain Cloutier, à l'est par M.TheUend, et à Lac Chat, in the rear by Germain Cloutier, on the east by Mr.l'ouest par G.Rousseau, avec bâtisses.TheUend and on the west by G.Rousseau, with buildings.Gérard Guillemette.21.87 21.87 61-60.Rang 1.Canton Mailhot.51-50, Range 1.Township of Mailhot.André Jeffrey.68.55 58.65 3, Rang 3, Canton Carignan.3, Range 3, Township of Carignan.Paul Laflamme.56.15 66.15 3, Ptie Rang 2, Canton Carignan, avec bâtisses.3, part of Range 2, Township of Carignan, with buildings.RenéLarivée.71.83 71.83 22, Ptie Rang 1, Canton Bourgeois, avec bâtisses.22, part of Range 1, Township of Bourgeois, with buildings.William Lord.30.00 30.00 15, Ptie Rang 1, Canton Boucher.15, part of Range 1, Township of Boucher.Mme-Mrs.Marie Josée Maltais.59.50 59.50 67 Ptie 2, Rang 1, Canton Mailhot, borné à l'ouest à 150 du 57, part 2 of Range 1, Township of Mailhot, bounded on the Boul.Ducharme, au nord à 191 pieds de la ligne de division west 150 feet from Ducharme Boulevard, on the north 191 des tots 56 et 57, au sud à 667 pieds de la ligne de division des feet from the separating line of lots 56 and 57, on the south 667 lots 57 et 68, & l'est par le résidu du lot 67.feet from the division Une of lots 57 and 68, on the east by the remainder of lot 67.André Nadeau.52.14 62.14 61-7, Rang 1, Canton Mailhot.51-7, Range 1, Township of Mailhot.M.Neault.36.56' 36.56 17-8, Rang 1, Canton Bourgeois, avec bâtisses.17-8, Range 1, Township of Bourgeois, with buildings.Fernand Sirois.37.58 37.58 43, Rang 1, Canton Boucher.43, Range 1, Township of Boucher.Laurier Tremblay.35.47 35.47 62, Ptie 2, Rang 1, Canton Mailhot.62, part 2 of Range 1, Township of Mailhot.Robert Tremblay.146.65 146.65 69-10, Rang 1, Canton Mailhot, avec bâtisses.69-10, Range 1, Township of Mailhot, with buildings.Charles Trudel.66.55 66.55 60, Ptie Rang 3, Canton Carignan, avec bâtisses.60, part of Range 3, Township of Carignan, with buildings.Germain Vallée.231.28 231.38 9 Ptie, Rang A, Canton Carignan, borné en front par la 9, part of Range A, Township of Carignan, bounded in front route 19, au nord par le résidu du lot 19, à l'est et au sud by Highway 19, on the north by the remainder of lot 19, on the par le lot 10, avec bâtisses.est and south by lot 10, with buildings.Secteur Sanmaur \u2014 Sanmaur Sector Robert Bousquet.» 42.86 $ 42.86 60-63, Canton Dessanne, avec bâtisses.60-53, Township of Dessane, with buildings.John Miller.55.82 65.82 Bloc C, Ptie Canton Dessane, avec bâtisses.Block C, part of the Township of Dessane, with buildings. 996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n' 4 Secteur La Tuque \u2014 La Tuque Sector \t\t\tTaxes\tTaxes\t Propriétaire\tDésignation\t\tmunie.\tscol.\tTotal \t\tFabrique\t\t' School\t Owner\tDesignation\t\tMunie.\t\t \t\t\ttaxes\ttaxes\t Robert Bellemare.S 6.66 S 14.89 S 39.94 S 61.39 29-435, Canton Mailhot.29-435, Township of Mailhot.Robert Bellemare.6.56 14.90 39.95 61.41 29-436, Canton Mailhot.29-436, Township «f Mailhot.Robert Bellemare.6.56 14.90 39.94 61.40 29-437, Canton Mailhot.29-437, Township of Mailhot.Robert Bellemare.6.57 14.90 39.95 61.42 29-438, Canton Mailhot.29-438, Township of Mailhot.Hillier & Mongrain.21.41 21.41 30-296, Ptie Canton Mailhot; lisière de 25' x 200' au sud 30-296, part of the Township of Mailhot, a strip of 25'x 200' dudit lot.south of the said lot.André Nadeau.693.47 592.52 2,540.66 3,826.65 33 Ptie est, Canton Mailhot.33,east partofthe Township of Mailhot.Un terrain de 150 x 150 borné au nord par Délisle Auto, A piece of land of 150 x 150, bounded on the north by Délisle au sud chemin Wayagamack, à l'est le résidu du lot 33, à l'ouest Auto, on the south by Wayagamack Road, on the east by the la route 19, avec bâtisses.remainder of lot 33, on the west by Highway 19, with buildings.Fernand Ouellette.192.10 764.41 956.51 27-558, Canton Mailhot, avec bâtisses.27-558, Township of Mailhot, with buildings.La Commission municipale de Québec, par un arrêté en date du 29 novembre 1971, a autorisé la Corporation municipale du comté de Champlain d'énumérer en abrégé les numéros cadastraux susmentionnés.Donné à Ste-Geneviève de Batiscan, le 7e jour du mois de janvier de l'année 1972.La sccrélaire-lrésorière, 44156-3-2-0 Fabienne Massicotte.Municipalité du comté de Missisquoi Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Yves Fortin, secrétaire-trésorier du conseil municipal du comté de Missisquoi, que les terrains ci-après décrits seront vendus à l'enchère publique, au rabais, au bureau dudit conseil, en la ville de Bedford, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi pour le paiement des taxes municipales, scolaires et autres charges dues aux municipalités ci-après mentionnées; sur les divers lots ou morceaux de terrain ci-après désignés à moins qu'elles ne soient payées avant la vente, avec les frais.The Québec Municipal Commission, by an Order dated November 29, 1971, authorized the Municipal Corporation of the county of Champlain to briefly enumerate the cadastral numbers above-mentioned.Given at St.Geneviève de Batiscan, the 7th day of the month of January, 1972.Fabienne Massicotte, 44156-3-2 Secretary-Treasurer.Municipality of the county of Missisquoi Public notice is hereby given by the undersigned Yves Fortin, Secretary-Treasurer of the Municipal council of the county of Missisquoi, that on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock a.m., in the Office of said Council, in the town of Bedford, shall be sold by public auction the lots of land thereafter described for the payment of Municipal School and other taxes or charges due to the Municipalities hereinafter mentioned, unless same be paid with the costs before the sale.Municipalité de Notre-Dame de Stanbridge \u2014 Municipality of Notre-Dame de Stanbridge Noms des propriétaires Nos officiels\tTaxes mun.\tTaxes scol.\tInt.et frais\tTotal Names of owners Official Nos.\tMun.taxes\tSchool taxes\tInt.and costs\t BaleLebelCo.744.\tS 3.13\t$ 1.85\t\t$ 4.98 Municipalité de Saint-Ignace de Stanbridge \u2014 Municipality of Saint Ignace de Stanbridge\t\t\t\t Forgues, Léonide.2256.\tS 2.60\t\t\t» 2.60 160.60 Fournier.Roger.2303-2304-2305-2306 & 2307.\t160.60\t\t\t QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.A 997 Municipalité de Saint-Ignace de Stanbridge {.tuile) \u2014Municipality of Saint Ignace de Stanbridge (continued) \t\t\tInt.\tTaxes\tTaxes\tet Nos officiels\tmun.\tscol.\tfrais Officiai Nos.\tMun.\tSchool\tInt.\ttaxes\ttaxes\tand \t\t\tcosts Noms des propriétaires Total Names of owners Tavan, Louis.P.2278, P.2279 & P.2280.$215.20 $ 234.51 $ 449.71 (rép.d'ég.) Boisvert, Vital.2277-2273-P.2276-2689 .68.74 68.74 (rép.d'ég.) Daudelin, Ulysse.P.857-3054-3052 .62.95 62.95 (rép.d'ég.) Morel, Léonard.2238-2239.21.84 21.84 (rép.d'ég.) Municipalité du canton de Stanbridge \u2014\tMunicipality of the township of Stanbridge\t \t.$ 37.68\t$ 37.68 Municipalité du canton de Bedford \u2014\tMunicipality of the township of Bedford\t Soûle, Doug.2157.\t.$ 35.30\t$ 35.30 Municipalité du village de Pbilipsburg -\t- Municipality of the village of Philipsburg\t Building Consultants Corp.P.40, P.41, 2a, 2a-l, 2a-2, 2a-3, $4,262.27 $1,639.25 $5,901.52 2a-4,2a-5, 2a-6, 2a-7, 2a-8.2a-9.76, 77, 78, 2.2-1, 2-2, P.84, P.106, P.107, P.115, P.5.Gendroska, Sylvester.P.49-38.35.56 35.56 Juratic, Filip.94.34 94.34 Municipalité de la paroisse de Saint-Armand-Ouest \u2014 Municipality of the parish of Saint Armand-West Boucher, Eugène.P.253.$ 14.70 $ 44.60 S 59.30 Davitt.William.206.214,218.114.00 191.15 305.15 Froidebise.Léon.91, P.385.,.102.30 347.14 449.44 Matthiesen.Karl.164, 169, 170, 171, 174.137.15 137.15 Plouffe, François.P.44.35.65 101.04 136.69 Shaw James .P.48-38-40-41, P.48-62-64, 159.40 473.65 633.05 P.48N.S.Tittemore, Chester.239,241,246,250,252.119.35 410.00 529.35 Wilson, Roger.P.50, AS.24,25.38.40 38.40 Gardner Albert.P.132-11, P.131-22.15.15 60.60 75.65 Bordo, Rovce.176,183.35.30 116.95 162.25 Border Lumber.P.48, P.48-54.18.75 18.75 Zimani, Joseph.P.101.40.25 40.25 Romahanyl.Gyozo.P- 101.118.20 118.20 Municipalité de Venise-en-Québec \u2014 Municipality of Venise-en-Québec Burns, Claudette.P.191-198.$ 8.20 $ 8.20 Joncas Normand.162-35.82.40 $ 48.92 $ 10.40 141.72 Choinlere, Jul^ni.P.153-34 .3.20 1.90 .50 6.60 Clairmont Louise .191-32.345.60 205.20 42.00 592.80 GaCTé Armaml 153:11-12.807.00 477.37 96.48 1,380.95 Gagné,'Armand (Chateau Venise) .153-5.1.708.80 1,014.60 205.65 2,928.95 Hefde Tiidrick.132-38 .31.40 2.60 34.00 998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S9 janvier 1972, 10i\" année, n° i Municipalité de Venis-en-Québec (tuile) \u2014 Municipality of Venise-en-Québec (continued) Noms des propriétaires\tNos officiels\tTaxes mun.\tTaxes scol.\tInt.et frais\tTotal Names of owners\tOfficiai Nos.\tMun.taxes\tSchool taxes\tInt.and costs\t Langlois.Daniel.\t.191-133.\t.* 34.65\tt 33.57\t$ 5.50\tS 73.72 \t.159-48.\t\t37.86\t\t111.71 \t.190-58.\t.98.40\t102.87\t15.82\t217.09 \t\t\t\t\t \tMunicipalité de Rainville \u2014\tMunicipality of Rainville\t\t\t Domingue.Maurice.2-8.Doré.Ravmond.226-16.O'Cain.James.P.141, P.158.Turcotte, Paul-André.P.237.32.44 3.64 9.04 16.19 t 396.92 188.65 S 429.36 3.64 9.04 204.84 Municipalité de la paroisse de Frelighsburg \u2014 Municipality of the parish of Frelighsburg Giasson, Mme G.S.P.394, P.398, P.398A, P.400, S 291.96 P.399 Marchessault, Yvan.278.46.63 Pigeon.André.192.193,195,197.873.73 Pigeon.Roland.182, 185, 186, P.206, P.212 .604.80 Richards, Mrs.Charles.420.8.74 Farnam, Bruce A.69.70, P.62.Gontovnick, Ben.290, P.292, 293, 294, 295.16.37 708.35 191.98 S 291.96 46.63 873.73 604.80 25.U 708.35 191.98 Municipalité du village de Clarenceville \u2014 Municipality of the village of Clarenceville Benway, Mrs.Florence.P.398.( 64.78 $ 61.94 S 126.72 Municipalité de la paroisse de Saint-Georges de Clarenceville \u2014 Municipality of the parish of Saint George of Clarenceville Benway, Estate Charles.P.270.Demers, Noel et Cameron, Victor .343.St-Germain.P.E.69.Yurkewich, Mrs.0.633, 205-3-4.Zelinsky.J.Boomhower, William.P.201.Hache?., Roger.194.Lachance, André.P.212.6.27 20.94 4.14 13.81 46.49 33.77 67.80 76.12 187.78 88.52 20.08 66.33 4.14 33.77 67 80 76.12 187.78 88.62 Municipalité de la paroisse de Saint-Thomas \u2014 Municipality of the parish of Saint Thomas P.4-22.\tf 19.88\tS 34.82 P.37 .\t61.00\t119.01 P.3-96, P.4-25-26.P.3-14-15,\t69.39\t93.48 P.4-142\t\t P.42-30.\t61.95\t148.48 P.42-69-71.\t67.90\t P.46.\t24.38\t5.51 21.\t3.00\t10.39 P.42.\t24.00\t30.72 P.46.\t\t18.67 54.70 170.01 162.87 200.43 67.90 29.89 13.39 64.72 18.67 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.A 999 Ville de Cowansville \u2014 Town of Cowansville \t\t\t\tInt.\t \t\tTaxes\tTaxes\tet\t Noms des propriétaires\tNos officiels\tmun.\tscol.\tfrais\tTotal Names of owners\tOfficial Nos.\tMun.taxes\tSchool taxes\tInt.and C08tS\t Brown, Warren D.Gogan.Est.Henry.Gratton, Mrs.Margaret H.Knight, Arthur J.Miller, Steven.Persons, E.J.Sayers, Edward.Thomas, Gerald.Vanderwerff, Hans.Pine Gables Nursing Home.Orbit Construction Corp.L.C.L.Enterprises Inc.Brome Land & Housing Develop.P.646-10, P.646-9.28, 29.P.107.P.436-159, P.436-160.124-303.P.52.P.14, P.8-1, 62-5, 62-6, 62-7, P.95, P.56, P.55, 46, P.51.P.286 P.293.99-5, 96-28.P.17, 638-46-47.P.468.307-116-189-117-190-166-240.P 307 P.481.307-58-105-017-110-111-112-184-185-186-187; 307-114-188; 307-191; 307-147; P.307-121-124; 307-165-164-163-241-242-246-243-245-130; P.307; 307-140; 468-167-307-132-135-137-138 ; 307-153-145-144.143.142.141 201.36 77.57 139.69 38.40 19.49 647.95 62.36 440.79 204.51 87.52 238.83 6.25 67.90 201.36 77.57 139.69 38.40 19.49 647.95 62.36 440.79 204.51 87.52 238.83 6.25 67.90 Ville de Dunham \u2014 Town of Dunham Bates, Merrill.Brown, Walter.Comeau, James Edgar.Guoziunas, K.V.McEathron, Mrs.M.L.Starkey, Arthur L.Weidlich, Miss E.Collins, Joseph.Gilmore, Patrick.Hauver.Kent.Hesketh, W.Hooper, Fernand.Howland, Peter.McAndrew, Miss E.Walters, James.P.322.P.113.P.249, 257.747, 748.P.692.P.381.P.842.P.552.P.654.P.666.P.555.P.555.P.555.P.550.P.655.S 13.75\tS 13.75 113.41\t113.41 256.87\t256.87 178.07\t178.07 40.05\t40.05 133.18\t133.18 35.13\t35.13 S 7.19\tS 7.19 7.02\t7.02 168.33\t168.33 37.22\t37.22 26.92\t26.92 90.08\t90.08 99.25\t99.25 99.29\t99.29 Donné à Bedford, ce cinquième jour de janvier mil neuf cent soixante-douze.Le secrétaire-trésorier, Yves Fortin, 43912-2-2-0 Corporation du comté de Missisquoi.Given at Bedford, on this fifth day of January, nineteen hundred and seventy-two.Yves Fortin, Secretary-Treasurer, 43912-2-2-0 Corporation of the county of Missisquoi.Municipalité du comté de Frontenac Avis public est par les présentes donné par Luc-Lin Bourque, secrétaire-trésorier du Conseil Municipal du comté de Frontenac, que les terrains ci-après décrits seront vendus à l'enchère publique à l'Hôtel de ville, en la ville de Lac-Mégantic, lieu où le conseil du comté tient ses séances, JEUDI le NEUVIÈME jour de Municipality of the county of Frontenac Public notice is hereby given by Luc-Lin Bourque, Secretary-Treasurer of the municipal council of the county of Frontenac, that the hereinafter mentionned lands will be sold at public auction, in the Town Hall, in the town of Lake Mégantic, place where the county council holds its sittings, THURSDAY the NINTH day 1000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n\" 4 MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi, pour les taxes municipales, scolaires et autres charges dues aux municipalités ci-après mentionnées, sur les divers lots ou morceaux de terrain ci-après désignés, à moins qu'elles ne soient payées avant la vente, avec les frais.of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for the municipal and school taxes and other charges due to the hereinafter municipalities upon the several lots or parcels of land hereinafter described unless the same be paid, with cost before the sale.Municipalité du canton de Lambton\u2014Municipality of the township of Lambton Propriétaires Owners\tNos des lots Nos.of lots\tNos des cad.Cad.Nos.\tRangs Ranges\tCantons Townships\tSuperficie ou mesures Area or measures\tTaxes munie.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tInt.et frais mun.Int.and Mun.costs\tTotal Bureau, Roland.\t32.\t\t8.\tLambton.Lambton.Lambton.\t\\Yt avec maison-with house 120.\tS 60.00 92.50 301.88\t\tS 3.00 4.50 11.95\tS 63.00 97.00 313.83 Gendron, Georges.\tPtie 6-B.Ptie 1-A.\t\t1-B.\t\t\t\t\t\t \t\t\tB.\t\t\\y2.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t Municipalité des Cantons Unis de Risborough et partie Marlow Municipality of \"Cantons Unis de Risborough & partie Marlow\" Dallaire Michel.Dupuis, Florian Dupuis, Florian Dupuis, Florian Nadeau, Isidore 4-A.1-A, Ptie 1-B.12-B____ 13-A____ 6-B.7 8 8 S 8 Risborough.Risborough Risborough Risborough Risborough.S 83\t60\t$ 178.67\t810\t11 83\t«n\t84.60\t4\t97 25\t20\t28.20\t1\t50 21\too\t23.50\t1\t30 92\tou\t94.00\t5\t¦12 $ 272.41 173.17 54.90 45.80 191.42 Municipalité de Marston-Canton \u2014 Municipality of Marston Township Poulin, Donald.Poulin, Donald.Poulin, Donald.Mueller, Mme-Mrs.Jane.Poser, Henry-August.Rouillard, Jacqueline.Mercier, Léo.Roy, Jacques.Pouliot, Camille.Doyon, Julien.Laurendeau, Roger.Lemieux, Lucien.O'Brien, Donald-.Rhéaume, Louis-Denis.Mercier, Léo.116.118.120.142.125.162.182.232.249.327.326.31.Ptie 138 264.161.3.\tMarston____\t100 acres.\tS 45.34\tS 11.44\t$ 6.54\t$ 63.32 3.\tMarston.\t100 acres.\t45.34\t11.44\t4.36\t61.14 3.\tMarston,.\t100 acres.\t45.34\t11.44\t\t56.79 3.-.\tMarston____\t300 x 225.\t42.50\t11.44\t3.20\t57.14 3.\tMarston.\t35 acres.\t85.00\t23.49\t8.50\t116.99 4.\tMarston.\t\t59.55\t10.02\t7.08\t76.65 4.\tMarston.\t100 acres.\t51.00\t26.99\t4.25\t77.99 6.\tMarston____\t100 acres.\t51.00\t11.44\t7.65\t70.09 5.\tMarston.\t100 acres.\t127.50\t71.09\t12.65\t211.24 7.\tMarston.\t\t89.25\t\t8.94\t98.19 5.\tMarston-\t100 x 100.\t157.25\t5.72\t17.28\t180.25 2.\tMarston____\t100 acres.\t66.15\t\t7.40\t73.55 3.\tMarston.\t\t63.73\t22.20\t5.94\t91.87 6.\tMarston.\t\t239.20\t46.89\t11.97\t298.06 4.\tMaraton____\t50 acres____\t38.25\t20.32\t3.20\t61.77 Municipalité de Notre-Dame-des-Bois \u2014 Municipality of Notre-Dame-des-Boia Moisan, Théodore.Moisan, Théodore.Laflamme, Alcide.L'Heureux, Robert St-James, Arthur.Ptie 23.Ptie 23.Ptie 34.Ptie 16.Ptie 18.6____ 6.6.4____ Chesham.Chesham.Chesham.Chesham.Chesham.17 x 27.500' x 800'.106' x 250'.50' x 100'.M acre.S 16.20\t\t 21.35\t$ 28.48\t 7.21\t17.80\t 10.00\t\t 16.20 21.35 28.48 25.01 10.00 Municipalité de Saint-Robert BeUarrnin \u2014 Municipalité of St-Robert Bellarmin Saint-Robert Metal Corp.Saint-Robert Metal Corp.1-A.\t 1-B.\t \t 16.Risborough.Marlow 100.100.S 14.84 179.67 t 14.84 179.67 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.L 1001 Municipalité de Saint-Samuel de Lac-Drolet \u2014 Municipality of Saint-Samuel of Lake Drolet Propriétaires\tNos des lots\tNos des cad.\tRangs\tCantons\tSuperficie ou mesures\tTaxes munie.\tTaxes scol.\tInt.et frais mun.\tTotal Owners\tNos.of lots\tCad.Nos.\tRanges\tTownships\tArea or measures\tMun.taxes\tSchool taxes\tInt.and Mun.costs\t \tPtie 128.\t\t2.\tGayhurst.\t\tS 15.85\t$ 20.63\t$ 4.09\tS 40.57 La maison seulement est vendue, pas le terrain.The House only is sold, not the land.Municipalité de Val Racine \u2014 Municipality of Val Racine Bergeron, Gaston.\tPtie 395.\t\t9.\tMarston.\tH.\t» 47.20\t\t\tS 47.20 \tPtie N.25\t\t1.\tChesham.\t50.\t16.70\t\t\t16.70 \t\t\t\t\t\t\t\t\t Municipalité de Winslow-Sud \u2014 Municipality of Winslow-South Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.Lapierre, Henri.\t81.\t\t5 S.O.5 S.O \t80.\t\t \t79____\t\t5 S.O \t77\t\t5 S.O \t78.\t\t5 S.O.5 S.O .\t76.\t\t \t78.\t\t4 S.O.4 S.O \t77.\t\t \t76.\t\t4 S.O \t75.\t\t4 S.O \tPtie 80.79.\t\t3 S.O \t\t\t3 S.O .\tPtie S.O.\t\t3 S.O.\t78.\t\t \t77.\t\t3 S.O \t76.\t\t3 S.O \t75.\t\t2 S.O.\t\t\t Winslow.Winslow.Winslow.Winslow.Winslow.Winslow.Winslow., Winslow.Winslow.Winslow.Winslow., Winslow.Winslow.Winslow.Winslow.Winslow.I 15.12 23.31 11.02 20.79 17.96 18.90 15.75 12.60 6.30 9.45 14.17 12.60 8.82 177.98 9.45 10.71 Municipalité de Saint-Augustin de Woburn \u2014 Municipality of St-Augustin of Woburn Lessard, Henri-Louis.\tPtie 3____ Ptie 1, 2-A.6.\t\t2.\tLouise.\t83 acres.60 acres.100 acres.81 acres.80 acres.100'x 100'.\tï 14.60 3.16 33.84 24.24 13.44 10.32\t$ 10.69 6.30 18.75 10.35 8.40 6.45\t$ 1.01 .50 3.07 2.39 1.13 .94\t$ 26.30 9.96 55.66 36.98 22.97 17.71 \t\t\t1.\tClinton.Woburn.Woburn.Woburn.Woburn.\t\t\t\t\t Lessard, Henri-Louis.\t\t\t7.\t\t\t\t\t\t \t\t\t7.\t\t\t\t\t\t \t11.\t\t7.\t\t\t\t\t\t \tPtie 12.\t\t7.\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t Municipalité de Frontenac \u2014 Municipality of Frontenac\t\t\t\t\t\t\t\t\t Vachon, Mme-Rrs.Réjeanne Paradis.\t44.\t\t1.\tDitchfield.\t61 acres .\tS 16.20\t\t\tS 16.20 Vraie copie.Donné à la ville de Lac-Mégantic, ce 5e jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 439062-2 o Luc-Lin Bourque.True copy.Given at the town of Lake Mégantic, this 5th day of January, 1972.Luc-Lin Boorque, 43906-2-2-o Secretary-Treasurer. 1002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10k- année, n° k Municipalité du comté de Beauce Je soussigné, Héliodore Rodrigue, secrétaire-trésorier du Conseil municipal du comté de Beauce, donne par les présentes avis public que les terres ou immeubles ci-dessous mentionnés seront vendus, par encan public, à Beauceville-Est, lieu où se tiennent les sessions du Conseil de comté, JEUDI le NEUVIÈME jour de MARS 1972 à DIX heures de l'avant-midi pour les cotisations et charges dues aux municipalités ci-dessous mentionnées, sur les divers lots plus bas désignés, à moins qu'elles ne soient payées, avec les frais, avant le jour ci-dessus indiqué.Municipality of the county of Beauce I undersigned, Héliodore Rodrigue, Secretary-Treasurer of the Municipal Council for the county of Beauce, give public notice that the lands or real estates hereinafter mentioned, will be sold by public auction at Beauceville-East, at the ordinary place of the sitting of the county council, on the NINTH day of MARCH 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for the asses-ments and charges due to the municipalities hereinafter mentioned upon the several lots hereinafter described, unless the same be paid, with costs, before the day of the sale aforesaid.Corporation municipale de St^ Victor de Tring \u2014 Municipal corporation of St-Victor de Tring \t\t\tTaxes\tTaxes\t Propriétaires\tRang\tNuméro cadastre\tmunie.\tscol.\t \t\t\t\t\tTotal Owners\tRange\tCadastral number\tMunie, taxes\tSchool taxes\t Bernard, Obvier.Ill P.408.* 2.17 $ 2.60 $ 4.77 Municipalité scolaire de l'Assomption \u2014 School municipality of l'Assomption Guay, Onésime.P.612.S 233.05 S 335.40 t 668.46 Municipalité du village de StrThéophile \u2014 Municipality of the village of St-Théophile Jacques.Athanase, St-Léon.P.69.$ 6.75 $ 19.69 t 26.44 Municipalité du village Linière \u2014 Municipality of the village of Linière Drouin, Germain, Aubin de l'isle.P.43.S 35.90 S 60.45 S 96.36 Corporation de la paroisse de St-Honoré \u2014 Corporation of the parish of St-Honoré Champagne, Jean-Claude.IX P.17C-18AB & 21AB.S 365.17 t 668.95 S 934.12 Corporation scolaire de Beauceville \u2014 School corporation of Beauceville Roy, Martin (Wilfrid).Poulin, Mme Gaétan, a/s Curateur Public.Hôtel Royal, a/s Léandre Bernard.Bernard Léandre.P.1530.i 40.54 $ 40.54 908-09-10-11.« 158.78 372.52 631.30 2322-1-2, 110-2-1, 2.360.42 6,858.57 9,218 99 117-1-1, 120-2-133, 114-1.1527-118-2-1.740.70 740 70 Municipalité du village de St-Victor\u2014 Municipality of the village of St-Victor Cloutier, Maurice.Jolicoeur, Jean-Raymond P.361 P.226 * 225.61 S 28.84 S 254.45 331.52 23.40 354.92 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1003 Municipalité scolaire de St-Honoré \u2014 School municipality of St-Honoré Propriétaires Rang\tTaxes Numéro cadastre munis.\tTaxes scol.\tTotal Owners Range\tCadastral number Munie.taxes\tSchool taxes\t \t21B.$\t442.12\t* 442.12 \t\t\t Commission scolaire de S.-C.-de-Jésus\t\u2014 School commission of S.-C.-de-Jésus\t\t \t14B.S 11S.90 S\t71.38\tS 187.28 Commission scolaire de St-Côme \u2014 School commission of St-Côme Crevicto Limitée, 1, Aubin de l'isle.Lepage, Benoit.4, sec.P.58A-B.P.13____ 233.74 S 265.09 11.10 11.10 Donné à Beauceville, ce 4 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 43911-2-2-0 Héliodore Rodrigue.Given at Beauceville, January 4, 1971.Héliodore Rodrigue, 43911-2-2-0 Secretary-Treasurer.Municipalité du comté de Richmond Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Me Camille Dupuis, secrétaire-trésorier de la municipalité du comté de Richmond, que les propriétés ci-après décrites seront vendues à l'enchère, au lieu ordinaire des séances du Conseil, à Richmond, Que., au bureau du soussigné, le JEUDI, le NEUVIÈME jour du mois de MARS, mil neuf cent soixante-douze (1972), à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, intérêts et les frais, plus les frais encourus subséquemment, à moins que lesdites taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.Municipality of the county of Richmond Public notice is hereby given by the undersigned Me Camille Dupuis, Secretary-Treasurer of the municipality of the county of Richmond, that the immoveable property hereinafter described, will be sold by public auction, at the ordinary place of the meetings of the Council, at Richmond, Que., at the office of the undersigned, on THURSDAY, the NINTH day of the month of MARCH, nineteen hundred and seventy-two (1972), at TEN o'clock in the morning, for the payment of municipal and school taxes, with the interest and costs, plus the costs subsequently incurred, unless the said taxes, interest and costs are paid before the sale.Canton de Cleveland \u2014 TownBhip of Cleveland Propriétaire Owner\tDésignation Description\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tTotal \t.Pt.17-A, Rang 12____\t8 18 20\t\t% 18.20 7.10 17.90 301.78 8.95 44.15 141.10 9.55 \t.28-D.Pt.28-A, Rang 14.\t7 10\t\t \t\t17 90\t\t \t.11-A, Pt.11-B, Rang 13____\t46 60\tS 255.18\t \t.Pt.14-F, Rang 16.\t\t\t \t\t\t\t Simoneau, Paul.\t.Pts.13-A.Pt.14-C.13-C, 14-B,\t141.10\t\t Plante, Marcel.\tRang 15.Lots 9-B & 9-C, Rang 9.\t\t\t \t\t\t\t Canton de Melbourne \u2014 Township of Melbourne Boulanger, Denis Pts.1-A, 1-C, 1-D, Rang 6 * 17.66 S 43.84 $ 61.60 1004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n' 4 Propriétaire\tDésignation\tTaxes munie.\tTaxes scol.\tTotal Owner\tDescription\tMunie, taxes\tSchool taxes\t Lemieux, Richard.\t.Lots 25-A, 25-C, Rang 7 Lots 25-A, Pt.26-A, Rang 8.Lot 12-18.Pt.12-19, Rang 8.\tS 37.96 105.95\t\tS 37.96 105.95 Municipalité d'Ulverton \u2014 Municipality of Ulverton\t\t\t\t Taylor, Bruce.Viger, Armand.Davies, John.Masters, Mme Arthur.Simpson, Estate.Veillon, Pierre.Lot 303 .8 64.83 Lot 204 & Pt.295.13.20 Pt.532.14.35 Lot 281.25.00 Lots 312 & Pt.313.113.78 Lots 323, 325, 326, 327, 330.331, Pt.452,56 332, 506, 509.64.83 13.20 14.35 25.00 113.78 452.56 Canton de Shipton \u2014 Township of Shipton Jacques.Raymond.Caron, Lucien.Ptie 20-A-19, Rang 3.Pt.n.s.19-F-2, Rang 3.Pt.n.s.20-B-l, Rang 3.Pt.n.s.20-A, Rang 3.S 64.48 253.36 54.48 253.36 St-François Xavier de Brompton \u2014 St-François Xavier de Brompton Boissé, Réjean.Ptie 5-C, rang 6.Paquet, Delourde.Ptie 12-B, Rang 2.15.44 25.30 8 15.44 25.30 Village de Greenlay \u2014 Village of Greenlay Gait Investment Corp.Ltd.Campbell, Wm.Lot 10-A-81, Rang 1.S 137.69 $ 1,228.90 $ 1,366.69 Lots 9-A & B, Rang 1.77.87 908.31 986.18 Village de Melbourne \u2014 Village of Melbourne McEinnon, Mrs.Wm.Lot 105.$ 24.28 $ 24.28 Ville de Danville \u2014 Town of Danville Tisluck, Jean Paul.Boucher, Mme Gaétan.Lefebvre, Daniel.Pt.287.$ 245.60 $ 356.87 $ 602.47 Pt.n.s.68.11.12, 13.173.83 199.49 373.32 Pties de 20 & 21.263.54 263.54 Ville de Windsor \u2014 Town of Windsor Mercier, Robert.St-Pierre, Henri.Lot No.297 et Pt.292.Ptie 893 (Canton Windsor).394.10 137.43 394.10 137.43 Ville de Richmond \u2014 Town of Richmond Fowler, Donald.Storie, Mrs.W.A.Storie, Mrs.W.A.Storie, Mrs.W.A.Storie, Mrs.W.A.Storie, Mrs.W.A.Lot 105-3.Pt.389.173, 175, 356, 13, 14.367.176.174.194.52 1,002.56 103.63 658.82 371.92 323.48 194.62 1,002.66 103.63 558.82 371.92 323.48 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.i 1006 Donné à Richmond, Que., ce cinquième jour du mois de janvier, mil neuf cent soixante-douze.Le secrétaire-trésorier, 43913-2-2-0 Mb Camille Dupuis.Lettres patentes Alfa-Omega Distributing Co.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Morris Golberg, huissier, 571, avenue Kenaston, Mont-Royal, Marguerite Elias, ménagère, épouse d'Edward Elias, 5475, Besshorough, et Mona Zalzal, secrétaire, fille majeure, 3555, Édouard-Montpetit, ces deux dernières de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer des articles, des produits et des marchandises de toutes sortes et en faire le commerce, sous le nom de « Alfa-Omega Distributing Co.Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715751 Phil Alter Sales Inc.Ventes Phil Alter inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Philip Alter, gérant des ventes, Jean Trachtenberg, administrateur, épouse dudit Philip Alter, tous deux de 1457, Franklin Drive, Laval, et Bonita Alter, ménagère, épouse de Peter Landesman, 7460, Kingsley, appartement 410, Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Manufacturer tous les textiles et leurs produits, ainsi que tous produits, articles et marchandises, sous le nom de « Phil Alter Sales Inc.\u2014 Ventes Phil Alter inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de 81 chacune.Le siège social de la compagnie est au 1457, Franklin Drive, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.\"44178 715682 Paul Baillargeon Productions Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres Given at Richmond, Que., this fifth day of the month of January, nineteen hundred and seventy-two.Me Camille Dupuis, 43913-2-2-0 Secretary-Treasurer.Letters Patent Alfa-Omega Distributing Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Ccmpanies and Cooperatives, incorporating: Morris Golberg, bailiff, 571 Kenastcn Avenue, Mount Royal, Marguerite Elias, housewife, wife of Edward Elias, 5475 Bessborough, and Mona Zalzal, secretary, spinster, 3555 Edouard Mcntpetit, the latter two of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in goods, wares and merchandise of every kind, under the name of \"Alfa-Omega Distributing Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715751 Phil Alter Sales Inc.Ventes Phil Alter inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, C< mpanies and Cooperatives, incorporating: Philip Alter, sales executive, Jean Trachtenberg, executive, wife of the said Philip Alter, both of 1457 Franklin Drive, Laval, and Bonita Alter, housewife, wife of Peter Landesman, 7460 Kingsley, Apt.410, Côte Saint-Luc, for the following purposes: To manufacture and deal in all textiles and products of textiles and all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"Phil Alter Sales Inc.\u2014 Ventes Phil Alter inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at 1457 Franklin Drive, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.4417S-0 715682 Paul Baillargeon Productions Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of June, 1971, have been issued by the Minister of Financial 1006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10b' année, n° b patentes, en date du 30e jour de juin 1971, constituant en corporation: Paul Baillargeon, musicien, Noëlla Baillargeon, épouse dudit Paul Baillargeon, tous deux de Sainte-Adèle, et Gabrielle Baillargeon, veuve de feu Paul Baillargeon, 146, des Bouleaux, Pointe-aux-Trembles, ces deux dernières ménagères, pour les objets suivants: Présenter, produire, mettre en scène, diriger et représenter des drames, comédies, opéras, pantomines, revues, parades et autres concerts, pièces musicales et autres, ballets, cirques, expositions et variétés et autres divertissements, sous le nom de « Paul Baillargeon Productions Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies tt coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 3599-1971 Balls Jeans Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de juillet 1971, constituant en corporation: Billy Mauer, 28, avenue Franklin, Mont-Royal, Seymour D.Steinman, 5706, avenue Parkhaven, Côte Saint-Luc, tous deux avocats, et Susan Brickland, secrétaire, célibataire, 5311 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer toutes sortes de textiles, fils, tissus, et produits d'iceux, fabriqués en tout ou en partie de la laine, du coton, de la rayonne, du nylon ou autres fibres naturelles ou synthétiques ou de toutes combinaisons d'iceiles, en faire le commerce, sous le nom de « Balls Jeans Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est au 500 place d'armes, local 1200, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 3771-1971 Burton's Importing Inc.Importations Burton inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Bernard Bosquet, administrateur, Yolande Burton, ménagère, épouse dudit Bernard Bosquet, tous deux de 7500, Trinidad, Brossard, et Susan Fisher, secrétaire, fille majeure, 4560, avenue Mayfair, Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer toutes marchandises, offrir les services connexes, et en faire le commerce, sous le nom de « Burton's Importing Inc.\u2014 Importations Burton inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Paul Baillargeon, musician, Noëlla Baillargeon, wife of the said Paul Baillargeon, both of Sainte-Adèle, and Gabrielle Baillargeon, widow of the late Paul Baillargeon, 146 des Bouleaux, Pointe-aux-Trembles, the latter two housewives, for the following purposes: To present, produce, manage, conduct and represent dramas, comedies, operas, pantomines, revues, promenade and other concerts, musical and other pieces, ballets, shows, exhibitions and variety and other entertainment, under the name of \"Paul Baillargeon Productions Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 3599-1971 Balls Jeans Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of July, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Billy Mauer, 28 Franklin Avenue, Mount Royal, Seymour D.Steinman, 5706 Parkhaven Avenue, Côte Saint-Luc, both advocates, and Susan Brickland, secretary, spinster, 5311 Sherbrooke Street West, Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in or with all kinds of textiles, yarns, fabrics and fabric products made, in whole or in part, of wool, cotton, rayon, nylon or any other fibre, natural or synthetic or of a combination thereof, under the name of \"Balls Jeans Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at 500 Place d'Armes, Suite 1200, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 3771-1971 Burton's Importing Inc.Importations Burton inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Bernard Bosquet, executive, Yolande Burton, housewife, wife of the said Bernard Bosquet, both of 7500 Trinidad, Brossard, and Susan Fisher, secretary, spinster, 4560 Mayfair Avenue, Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all goods and services, under the name of \"Burton's Importing Inc.\u2014 Importations Burton inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of the par QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1007 ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 390 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Brossard, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions-financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 715810 Café André inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour d'août 1971, constituant en corporation: George Alexiou, 242, rue Lechasseur, Beloeil, Dimitrios Arvanitakis, tous deux restaurateurs, et Panagiotis Tsonos, cuisinier, ces deux derniers de 172, 4e avenue, Verdun, pour les objets suivants: Exploiter des commerces de restaurants, hôtels, motels de toutes sortes, sous le nom de « Café André inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie est 2077, rue Victoria, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 715626 Cana Explorations Limited (No personal liability) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Franklin Chan, ingénieur professionnel, 4973, Olivier, Picrrefonds, Denyse Marcoux, secrétaire, célibataire, 1488, rue Galt, Richard McCono-my, 4790, Côte des Neiges, Guy-E.Boisvert, 4976, Glencairn, tous trois de Montréal, et G.Harold Pickel, 47, Arlington, Westmount, ces trois derniers avocats, pour les objets suivants: Faire des recherches et explorations aux fins de découvrir des mines et minerais, sous le nom de « Cana Explorations Limited » (No personal liability), avec un capital-actions divisé en 5,000,000 d'actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est à 800, ouest, boulevard Dorchester, local 2610, Westmount, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 715454 Canaper Holdings Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres value of $1 each and 390 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company is at Brossard, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715810 Café André inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: George Alexiou, 242 Lechasseur Street, Beloeil, Dimitrios Arvanitakis, both restaurant operators, and Panagiotis Tsonos, cook, the latter two of 172, 4th Avenue, Verdun, for the following purposes: To operate restaurants, hotels and motels of any kind, under the name of \"Café André inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,500 common shares of the par value of $10 each and 500 preferred shares of the par value of $50 each.The head office of the company is at 2077 Victoria Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715626 Cana Explorations Limited (No personal liability) Notice is given that under the provisions of the Mining Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Franklin Chan, professional engineer, 4973 Olivier, Pierrefonds, Denyse Marcoux, secretary, spinster, 1488 Gait, Richard McConomy, 4790 Côte des Neiges, Guy-E, Boisvert, 4976 Glencairn, all three of Montreal, and G.Harold Pickel, 47 Arlington, Westmount, the latter three attorneys, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals, under the name of \"Cana Explorations Limited\" (No personal liability), with a capital stock divided into 5,000,000 common shares without par value.The head office of the company is at 800 Dorchester Boulevard West, Suite 2610, Westmount, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715454 Canaper Holdings Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial 1008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n\" 4 patentes, en date du 12e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Jocelyne Villemure, secrétaire, épouse de Pierre-Paul White, 1070 Terrasse des Saules, Longueuil, André Valiquette, 59 Franklin, et Daniel Kochenburger, 1545 boulevard Graham, ces deux derniers avocats, de Mont Royal, pour les objets suivants : Exercer les affaires d'une compagnie de placement, sous le nom de « Canapcr Holdings Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à 612 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financièn s, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715388 Chapotal Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: I.David Fleming, 65 Belvedere Road, Joseph Di Clementi, 4300 boulevard de Maisonneuve, tous deux de Westmount, et Henri W.Laurier, 110 Brixton, Saint-Lambert, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie d'actionnaires capitalistes, financiers, courtiers et agents, sous le nom de « Chapotal Corporation », avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est à 620 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715263 Clinton Insurance Inc.Assurances Clinton inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour de novembre 1971, constituant en corporation: James G.Wright, 3164, Le Boulevard, Robert-P.Godin, 4222, avenue Beaconsfield, tous deux de Montréal, Richard J.F.Bowie, 181, avenue Morrison, Mont-Royal, tous trois avocats, et James G.Jutras, commis en droit, 216, avenue Lawrence, Greenfield Park, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'agents et de courtiers d'assurances, sous le nom de « Clinton Insurance Inc.\u2014 Assurances Clinton inc.», avec un capital divisé en 10,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 81 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 716124 Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jocelyne Villemure, secretary, wife of Pierre-Paul White, 1070 Terrasse des Saules, Longueuil, André Valiquette, 59 Franklin, and Daniel Kochenburger.1545 Graham Boulevard, the latter two lawyers, of Mount Royal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Canapcr Holding Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of 81 each.The head office of the company is at 612 St.James Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 715388 Cbapotal Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: I.David Fleming, 65 Belvedere Road, Joseph Di Clementi, 4300 de Maisonneuve Boulevard, both of Westmount, and Henri W.Laurier, 110 Brixton, Saint-Lambert, all three attorneys, for the following purposes: To carry on business as investors, capitalists, financiers, brokers and agents, under the name of « Chapotal Corporation», with a capital stock divided into 1,000 common shares without par value.The head office of the company is at 620.St.James Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715263 Clinton Insurance Inc.Assurances Clinton inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: James G.Wright, 3164 The Boulevard, Robert-P.Godin, 4222 Beaconsfield Avenue, both of Montreal, Richard J.F.Bowie, 181 Morrison Avenue, Mount Royal, all three advocates, and James G.Jutras, law clerk, 216 Lawrence Avenue, Greenfield Park, for the following purposes: To carry on business as agents and insurance brokers, under the name of \"Clinton Insurance Inc.\u2014 Assurances Clinton inc.\", with a capital stock divided into 10,000 common shares without par value and 30,000 preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 716124 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1009 Colossus Land Investments Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour d'octobre 1971, constituant en corporation : Andrée Dupuis, épouse de Joseph Anglade, 4704 Lafontaine, Pauline Laterreur, 4586 Iberville, toutes deux de Montréal, et Carolyn Schan-field, 2782 McWillis, Saint-Laurent, ces deux dernières filles majeures, toutes trois secrétaires, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de portefeuille, de recherche et de construction, sous le nom de « Colossus Land Investments Corp.», avec un capital divisé en 40,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est 1255 rue Université, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715260 .Cypihot Gym Equipment Inc.Equipement de gymnase Cypihot inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Louis Schiff, 5747 Avenue Blossom, J.Roy Hoffman, 5615 Pinedale, tous deux de Côte Saint-Luc, et Martin Green, 982 rue Grou, Saint-Laurent, tous trois avocats, pour les objets suivants: Manufacturer des équipements de gymnase de tous genres et de toutes descriptions, en faire le commerce, sous le nom de « Cypihot Gym Equipment Inc.\u2014 Équipement de gymnase Cypihot inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de $1 chacune et 390 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 5820 Charlevoix, Montréal Nord, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715011 Colossus Land Investments Corp- Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Andrée Dupuis, wife of Joseph Anglade, 4704 Lafontaine, Pauline Laterreur, 4586 Iberville, both of Montreal, and Carolyn Schanfield, 2782 McWillis, Saint-Laurent, the latter two filles majeures, all three secretaries, for the following purposes: To carry on the business of a holding, research and building company, under the name of \"Colossus Land Investments Corp.\", with a capital stock divided into 40,000 common shares without par value.The head office of the company is at 1255 University Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715260 Cypihot Gym Equipment Inc.Equipement de gymnase Cypihot inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of September, 1971.have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Louis Schiff, 5747 Blossom Avenue, J.Roy Hoffman, 5615 Tinedale, both of Côte Saint-Luc, and Martin Green, 982 Grou Street, Saint-Laurent, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in gymnasium equipment of any kind and description, under the name of \"Cypihot Gym Equipment Inc.\u2014 Équipement de gymnase Cypihot inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 5820 Charlevoix, Montreal North, judicial district of Montreal.Lb-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715011 Dan River Mining & Exploration Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de novembre 1971, constituant en corporation: Michael Marion Zebeski, administrateur, 19, Vanguard Drive, Islington, Esther Elizabeth Rennalls, secrétaire juridique, fille majeure, 31, Marowyne Drive, et Irving Murray Noble, comptable, 749, avenue Steeles ouest, ces deux derniers de Willowdale, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses spécialités un commerce d'exploitation minière, de broyage, de réduction et de mise en valeur, sous le nom de « Dan River Mining & Exploration Inc.», avec un capital divisé en 3,000,000 d'actions ordinaires sans valeur au pair.Dan River Mining & Exploration Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michael Marion Zebeski, executive, 19 Vanguard Drive, Islington, Esther Elizabeth Rennalls, legal secretary, spinster, 31 Marowyne Drive, and Irving Murray Noble, accountant, 749 Steeles Avenue West, the latter two of Willowdale, for the following purposes: To carry on in all its branches the business of mining, milling, reduction and development, under the name of \"Dan River Mining & Exploration Inc.\", with a capital stock divided into 3,000,000 common shares without par value. 1010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S9 janvier 197S, 104' année, n\" 4 Le siège social de la compagnie est 50, place Créma-zie, suite 800, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 716132 Dave's Quality Meat Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour d'octobre 1971.constituant en corporation: Nathan A.Levitsky, uvocat, 17 Normandy Drive, Mont Royal, Madeleine Tavrizian, épouse de Kcvork Tavrizian, 7915 de Normanville, et Dorothy Gunston, épouse divorcée de Stanley Gunston, 1444 Mackay, app.903, ces deux dernières secrétaires, de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter le commerce de produits, articles et marchandises de toutes sortes et de toutes descriptions se rapportant au commerce d'épiceries et de viande, sous le nom de « Dave's Quality Meat Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Lasalle, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715482 De Vimy Pictures Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Jean-Marie Biais, avocat, 327 des Prés, Laval, Hélène Roux, épouse de Michel Gagnon, 6994, 16e Avenue, app.3, et Lucille Matte, fille majeure, 7094, 14e Avenue, ces deux dernières secrétaires, de Montréal, pour les objets suivants: Diriger une entreprise générale de publicité, de réclame et d'agence de nouvelles, sous le nom de « De Vimy Pictures Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,900 actions privilégiées de $10 chacuue.Le siège social de la compagnie est à 210 ouest, rue St-Jacques, chambre 800, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minùitre des institutions financières, compagnies cl coopératives, I,s-Philippe Bouchard.44178 715276 Elite Screen Process Company Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie ue la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Wendell H.Laidley, 250 Avenue Clarke, Westmount, Gordon M.Sclig, 2165 Collège, The head office of the company is at 50 Place Cré-mazie.Suite 800, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-c 716132 Dave's Quality Meat Inc.Notice is given that under Part I ofthe Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Nathan A.Levitsky, advocate, 17 Normandy Drive, Mount Royal, Madeleine Tavrizian, wife of Kevork Tavrizian, 7915 de Normanville.and Dorothy Gunston, wife divorced of Stanley Gunston, 1444 Mackay, Apt.903, the latter two secretaries, of Montreal, for the following purposes: To deal in goods, wares and merchandise of all kinds or descriptions connected with groceries and meats, under the name of \"Dave's Quality Meat Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Lasalle, judicial district of Montreal.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715482 De Vimy Pictures Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of October, 1971, have been issued l>y the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Marie Biais, advocate, 327 des Prés, Laval, Hélène Roux, wife of Michel Gagnon, 6994, 16th Avenue, Apt.3, and Lucille Matte, spinster, 7091.14th Avenue, the latter two secretaries, of Montreal, for tin-following purposes: To conduct a general advertising, press agency and publicity business, under the name of \"De Vimy Pictures Inc.\".with a total capital stock of $40,000.divided into 1,000 common shares oi $1 each and 3,900 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 210 St.James Street West, Room 800, Montreal, judicial district of Mont real.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.4417S-0 715276 Elite Screen Process Company Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Wendell H.Laidley, 250 Clarke Avenue! Westmount, Gordon M.Selig, 2165 College, SainU QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.A 1011 Saint-Laurent, et Martin H.Campbell, 4851 Avenue Draper, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Imprimer, graver en relief, graver, lithographier, faire des clichés, clicher par électrotypie, photographier, photolithographier, photograver, similigraver, graver sur zinc, graver sur cire, imprimer et reproduire suivant le procédé de sérigraphie, sous le nom de « Elite Screen Process Company Ltd.», avec un capital total de S40.000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à 1236 rue Elizabeth, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minisire des institutions financières, compagnies et cooperatives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 716516 Famous Delly House Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Guido Broccoli, 462, Paquin, Lasalle, Salvatore Broccoli, 11831, James Morrice, Montréal, Michel Tatsis, 615, Hudson, #15, et Pieris Aronis, 615.Hudson, #1, ces deux derniers de Côte Saint-Luc, tous quatre restaurateurs, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de restaurant, sous le nom de « Famous Delly House Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions catégorie «A» de $1 chacune, 10,000 actions catégorie « B » de $1 chacune, 10,000 actions privilégiées catégorie « A » de $1 chacune et 10,000 actions privilégiées catégorie « B » de $1 chacune.Le siège social île la compagnie est au Centre Commercial St-Martin, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715583 Fandon Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de juin 1971, constituant en corporation: Florence Katz, ménagère, épouse de Irwin Laufer, 6595, Côte St-Luc, Angi Roscnzweig, institutrice, épouse de Martin Bloom, 5460, Sunny-brooke, tous deux de Montréal, et Donna Steiner, physiothérapeute, épouse de Joel Weitzman, 5501, Adalbert, Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Manufacturer des appareils mécaniques et électriques, dispositifs nécessaires pour l'entretien des automobiles et moteurs de toutes sortes, en faire le commerce, sous le nom de « Fandon Corporation », avec un capital total de $35,000, divisé en 34,000 actions ordinaires de $1 chacune et 1,000 actions privilégiées de $1 chacune.Laurent, and Martin H.Campbell, 4851 Draper Avenue, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To print, emboss, engrave, lithograph, sterotype, electrotype, photograph, pbotolithograph, photo-engrave, halftone engrave, zinc etch, wax engrave, print and reproduce by silk screen process, under the name of \"Elite Screen Process Company Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1236 St.Elizabeth Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715516 Famous Delly House Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guido Broccoli, 462 Paquin, Lasalle, Salvatore Broccoli, 11831 James Morrice, Montreal, Michel Tatsis, 615 Hudson, #15, and Pieris Aronis, 615 Hudson, #1, the latter two of Côte Saint-Luc, all four restaurateurs, for the following purposes: To operate a restaurant, under the name of \"Famous Delly House Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 class \"A\" shares of $1 each, 10,000 class \"B\" shares of $1 each, 10,000 class \"A\" preferred shares of SI each and 10,000 class \"B\" preferred shares of $1 each.The head office of the company is at St.Martin Shopping Centre, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 715583 Fandon Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of June, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Florence Katz, housewife, wife of Irwin Laufer, 6595 Côte St.Luc, Angi Rosenzweig, teacher, wife of Martin Bloom, 5460 Sunnybrooke, both of Montreal, and Donna Steiner, physiotherapist, wife of Joel Weitzman, 5501 Adalbert, Côte Saint-Luc, for the following purposes: To manufacture and deal in mechanical and electrical apparatus and devices necessary in the maintenance of automobiles and motors of all kinds, under the name of \"Fandon Corporation\", with a total capital stock of $35,000, divided into 34,000 common shares of $1 each and 1,000 preferred shares of $1 each. 1012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n\" 4 Le siège social de la compagnie est 5501, rue Adalbert, Côte Saint-Luc, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 3458-1971 Fastat Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de septembre 1971, constituant en corporation: John Matthews, technicien, 7861, 23e Avenue, Linda Yule, statisticien, célibataire, 6858, 24e Avenue, tous deux de Montréal, et William Taylor, artiste commercial, 1471, avenue Crawford Bridge.Verdun, pour les objets suivants: Exercer un commerce qui consiste à reproduire des copies par les procédés de la photographie et du photostat, sous le nom de « Fastat Inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est au 1253, avenue du Collège McGill, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715100 Fernando's Delicatessen Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi aes compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour d'août 1971, constituant en corporation: Fernando Fernandes, restaurateur, Panagiota Fernandes, ménagère, épouse dudit Fernando Fernandes, tous deux de 453, Notre-Dame de Fatima, Laval, et Peter Thomakou, homme d'affaires, 1050 ouest, rue Bernard, Montréal, pour les objets suivants : Exploiter un commerce de restaurant, sous le nom de « Fernando's Delicatessen Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions catégorie « A » de $1 chacune, 10.000 actions catégorie « B » de $1 chacune, 10,000 actions privilégiées catégorie « A » de $1 chacune et 10,000 actions privilégiées catégorie « B » de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est au 856 est rue Ste-Catherine Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714290 Guy Fortier Holding Corporation Ltd.Corporation de Gestion Guy Fortier, ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres The head office of the company is at 5501 Adalbert Street, Côte Saint-Luc, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 3458-1971 Fastat Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: John Matthews, technician, 7861, 23rd Avenue, Linda Yule, statistician, spinster, 6S58, 24th Avenue, both of Montreal, and William Taylor, commercial artist, 1471 Crawforo Bridge Avenue, Verdun, for the following purposes: To carry on the business of making photostatic and photographic copies, under the name of \"Fastat Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1.000 common shares of the par value of $10 each and 3,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at 1253 McGill College Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715100 Fernando's Delicatessen Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 17th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Fernando Fernandes, restaurateur, Panagiota Fernandes, housewife, wife of the said Fernando Fernandes, both of 453 Notre-Dame-de-Fatima, Laval, and Peter Thomakou, businessman, 1050 Bernard West, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a restaurant, under the name of \"Fernando's Delicatessen Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 10.000 class \"A\" shares of $1 each, 10,000 class \"B\" shares of SI each, 10,000 class \"A\" preferred shares of $1 each and 10,000 class \"B\" preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 856 St.Catherine Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714290 Guy Fortier Holding Corporation Ltd.Corporation de Gestion Guy Fortier.ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Finan- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1013 patentes, en date du 30e jour d'août 1971, constituant en corporation ; Guy Fortier, industriel, Juliette Rainville, ménagère, épouse dudit Guy Fortier, tous deux de 511, avenue Roslyn, Westmount, et Maurice Martel, avocat, 1301, avenue St-Viateur, Outremont, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de portefeuille, sous le nom de « Guy Fortier Holding Corporation, Ltd.\u2014 Corporation de Gestion Guy Fortier, ltée », avec un capital total de $2,000,000,'divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune, 199,690 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées catégorie « B » d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est au 511, avenue Roslyn, Westmount, district judiciaire de Montreal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et.coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714545 cial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guy Fortier, industrialist, Juliette Rainville, householder, wife of the said Guy Fortier, both of 511 Roslyn Avenue, Westmount, and Maurice Martel, lawyer, 1301 St-Viateur Avenue, Outremont, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"Guy Fortier Holding Corporation, Ltd,\u2014 Corporation de Gestion Guy Fortier, ltée\", with a total capital stock of $2,000,000, divided into 100 common shares of the par value ot $1 each, 199,690 class \"A\" preferred shares of the par value of $10 each and 3,000 class \"B\" preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at 511 Roslyn Avenue, Westmount, judicial district of Montreal.Ls-PniLirPE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 714545 Guardsman Equipment Leasing (Québec) Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour de décembre 1971, constituant en corporation: Adrien-R.Paquette, 212, avenue Bloomfield, Outremont, Benoit Groleau, 7130, Lacordaire, Saint-Léonard, tous deux avocats, et Denise Paquette, secrétaire, célibataire, 9915, Esplanade, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de location d'omnibus, taxis, fardiers, automobiles, autobus, camions, camionnettes, ou autres véhicules de transport privés ou publics, sous le nom de « Guardsman Equipment Leasing (Québec) Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 36,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714864 Guybrooke Trading Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 25e jour d'août 1971, constituant en corporation: Michel Duranceau, 22, Les Ormes, Laval, Michel Blouin, 3328, avenue Troie, Montréal, Daniel Kochenburger, 1545, boulevard Graham, et André Valiquette, 59, Franklin, ces deux derniers de Mont-Royal, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Manufacturer toutes sortes de marchandises et en faire le commerce, sous le nom de « Guybrooke Trading Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune .Guardsman Equipment Leasing (Québec) Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Adrien-R.Paquette, 212 Bloomfield Avenue, Outremont, Benoit Groleau, 7130 Lacordaire, Saint-Léonard, both lawyers, and Denise Paquette, secretary, spinster, 9915 Esplanade, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of lessors of omnibuses, cabs, drays, taxicabs, motor buses, auto drays, motor trucks or other private or public conveyances, under the name of \"Guardsman Equipment Leasing (Québec) Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of the par value of $1 each and 36,000 preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714864 Guybrooke Trading Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michel Duranceau, 22 Les Ormes, Laval, Michel Blouin, 3328 Troie Avenue, Montreal, Daniel Kochenburger, 1545 Graham Boulevard, and André Valiquette, 59 Franklin, the latter two of Mount Royal, all four lawyers, for the following purposes: To manufacture and deal in goods of every kind and nature, under the name of \"Guybrooke Trading Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each. 1014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Le siège social de la compagnie est au 612 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714480 H.K.Truck & Trailer Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour d'août 1971, constituant en corporation: Max S.Kaufman, 574, Claremont, Westmount, Oscar Respitz, 4945, Glencairn, Sydney B.Sederoff, 80, Crestwood, et E.Stephen Segal, 5625, Clanranald, ces trois dernières de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Posséder et gérer des garages, véhicules automobiles, boutiques de réparation et réparer, repeindre, remettre au point, améliorer et entretenir les moteurs, automobiles, camions, remorques et véhicules-moteurs de toutes sortes et descriptions, sous le nom de « H.K.Truck & Trailer Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ininistre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714532 H.R.H.Investments Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: I.David Fleming, 65, chemin Belvédère, Westmount, Joseph Di dementi, 4300, boulevard de Maisonneuve, Montréal, et Hcnri-W.Laurier, 110, Brixton, Saint-Lambert, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer des affaires à titre d'actionnaires, capitalistes, financiers, courtiers et agents, sous le nom de « H.R.H.Investments Ltd.», avec un capital-actions divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est au 620 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715261 Hanbec Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de juillet 1971, constituant en corporation: Humphrey Kassie, administrateur, 658, avenue Lansdowne, B.Robert Benson, 652 Lansdowne Avenue, tous deux de Westmount, Robert The head office of the company is at 612 St.James Street West, Suite 703, Montreal, judicial district of Montreal.- Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714480 H.K.Truck & Trailer Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Max S.Kaufman, 574 Claremont, Westmount, Oscar Respitz, 4945 Glencairn, Sydney B.Sederoff, 80 Crestwood, and E.Stephen Segal, 5625 Clanranald, the latter three of Montreal, all advocates, for the following purposes: To own and operate garages, motor vehicle repair shops, and to repair, repaint, overhaul, renovate, improve and maintain motors, motor cars, trucks, trailers and motor vehicles of every kind and description, under the name of \"H.K.Truck & Trailer Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714532 H.R.H.Investments Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: I.David Fleming, 65 Belvedere Road, Westmount, Joseph Di Clementi.4300.de Maisonneuve Boulevard, Montreal, and Henri-W.Laurier, 110 Brixton, Saint-Lambert, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as investors, capitalists, financiers, brokers and agents, under the name of \"H.R.H.Investments Ltd.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without par value.The head office of the company is at 620 St.James Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715261 Hanbec Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of July, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Humphrey Kassic, executive, 658 Lansdowne Avenue, B.Robert Beuson, 652 Landsdowne Avenue, both of Westmount, Robert H.Dolman, 6505 Côte St. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.4 1015 H.Dolman, 6505, chemin Côte Saint-Luc, Côte Saint-Luc, tous deux avocats, Ann Barry, épouse de Peter Lyle Barry, 5266, avenue Connaught, et Camille Le Blanc, fille majeure, 2417 est.Park Row, ces deux dernières secrétaires, de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de propriétés immobilières, sous le nom de « Hanbec Inc.».avec un capital total de S40.000, divisé en 20,000 actions ordinaires de SI chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à 4875, chemin Dufferin, Montréal, district, judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 3899-1971 Hank's Restaurant Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Serge Crochetière, 5961, Des Écores, Elio Ccrundolo, 1819 est, Jean-Talon, local 100, tous deux avocats, de Montréal, et Solange Cerundolo, secrétaire, épouse dudit Elio Cerundolo, 1050, Montpellier, Laval, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de restaurant, cafeteria, « delicatessen », liqueurs douces, comptoir-lunch, étalages pour tabac, journaux et fruits, salles à dîner, approvisionneurs et pourvoyeurs licenciés, hôteliers, taverniers et aubergistes, sous le nom de « Hank's Restaurant Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune et 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est au 9250, boulevard St-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 714713 Harem Restaurant Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Venizelos Mandas, 6005, avenue du Parc, Nesdet Cicek, 2975, Goyer, #14, Antonio Psa-roudis, 5629, Jeanne-Mance, Ihsan Bodur, 2985, Goyer, #14, et Sabahattin Sahin, 5695 ouest, rue St-Jacques, tous restaurateurs, de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de restaurateurs, sous le nom de « Harem Restaurant Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de $1 chacune.Luc Road, Côte Saint-Luc, both attorneys, Ann Barry, wife of Peter Lyle Barry.5266 Connaught Avenue, and Camille Le Blanc, fille majeure, 2417 Park Row East, the latter two secretaries, of Montreal, for the following purposes: To deal in all kinds of immoveable property, under the name of \"Hanbec Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 4875 Dufferin Road, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 3899-1971 Hank's Restaurant Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Serge Crochetière, 5961 des Ecores, Elio Cerundolo, 1819 Jean-Talon East, Suite 100, both advocates, of Montreal, and Solange Cerundolo, secretary, wife of the said Elio Cerundolo, 1050 Montpellier, Laval, for the following purposes: To carry on the business of restaurant, cafeteria, delicatessen, soda-fountain, lunch counter refreshment, tobacco, news and fruit stands, dining-room, caterers, licensed victuallers, hotels, tavern and innkeeper, under the name of \"Hank's Restaurant Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 9250 St-Law-rence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 714713 Harem Restaurant Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Venizelos Mandas, 6005 Park Avenue, Nesdet Cicek, 2975 Goycr, #14, Antonio Psaroudis, 5629 Jeanne-Mance, Ihsan Bodur, 2985 Goyer, #14, and Sabahattin Sahin, 5695 St.James Street West, all restaurateurs, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Harem Restaurant Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 20,000 preferred shares of $1 each. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Le siège social de la compagnie est au 6001, avenue du Parc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715268 Harley Plaza Restaurant Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Louis I.chrcr, homme d'affaires, Doris Mirotchnick, ménagère, épouse dudit Louis Lehrer, et Harold Lehrer, avocat, tous trois de 2040, rue Scott, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de restaurant, sous le nom de « Harley Plaza Restaurant Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 7421, rue Harley, Montréal-ouest, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715221 Harlco Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour d'août 1971, constituant en corporation : Samuel Brinker, grossiste, Edna Brinkcr, ménagère, épouse dudit Samuel Brinker, tous deux de 1948, chemin Norway, Mont-Royal, et Lewis Brinker, gentilhomme, 6905, avenue Victoria, Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer tous genres d'appareils de chauffage, à des fins industrielles, résidentielles ou commerciales, en faire le commerce, sous le nom de « Hartco Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est au 9740, Jeanne-Manee, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714209 Hayward & Son Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Douglas Hayward, James Hayward, et Barbara Newell Anthony, épouse dudit James Hayward, tous trois cuisiniers pâtissiers, de 113, Wcsthill, Saint-Bruno-de-Moutarville, pour les objets suivants: The head office of the company is at 6001 Park Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715268 Harley Plaza Restaurant Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Louis Lehrer, businessman, Doris Mirotchnick, housewife, wife of the said Louis Lehrer, and Harold Lehrer, lawyer, all three of 2040 Scott Street, Saint-Laurent, for the following purposes: To operate a restaurant, under the name of \"Harley Plaza Restaurant Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 7421 Harley Street, Montreal West, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 715221 Hartco Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Samuel Brinker, wholesaler, Edna Brinker, housewife, wife of the said Samuel Brinker, both of 1948 Norway Road.Mount Royal, and I.ewis Brinker, gentleman, 6905 Victoria Avenue, Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all types of industrial, residential and commercial heating equipment, under the name of \"Hartco Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 9740 Jeanne-Mance, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714209 Hayward & Son Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters_patent, bearing date the 20th day of September.1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Douglas Hayward, James Hayward, and Barbara Newell Anthony, wife of the said James Hayward, all three pastry-cooks, of 113 Westhill, Sain't-Bruno-de-Montarvillc, for the following purposes; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, 'No.4 1017 Fabriquer du pain, des gateaux, pâtisserie et tous articles d'alimentation produits par la cuisson en, faire le commerce, sous le nom de « Hayward & Son Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est au centre commercial St-Bruno, Saint-Bruno-dc-Montarville, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies, et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714960 Institutional Management and Supply Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de novembre 1971, constituant en corporation: Antoine Paré, avocat, 695, Gros-venor, Westmount, Susan Alcock, 4311, Old Orchard, app.1607, et Charlotte-C.Roux, 3281 Forest Hill, app.9, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Procurer aux hôpitaux, aux hôtels, aux maisons de convalescents, aux foyers pour enfants et aux autres institutions des services et commodités comprenant des services de buanderie, des services de traiteurs et tout autre service utilisé par des établissements du genre, sous le nom de « Institutional Management and Supply Corporation », avec un capital total de 840,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715924 Koran Explorations Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Thomas Charles Hayhurst Baldwin, avocat, 10 Kimlock Crescent, Don Mills, Margaret Nancy Bannister, 58, avenue Burgess, Jacqueline Kennedy, 1921A est, rue Queen, Millicent Liburd, 100, avenue Gamble, app.105, toutes trois célibataires, et Rita Seifert, épouse de Wolfgang Paul Seifert, 70, avenue Délisle, app.304, ces quatre derniers secrétaires juridiques, de Toronto, pour les objets suivants: Faire des recherches et explorations aux fins de découvrir des mines et minerais, sous le nom de « Koran Explorations Limited », avec un capital-actions divisé en 5,000,000 d'actions sans valeur au pair.To manufacture and deal in bread, cakes, pastry and ail articles of food produced by baking, under the name of \"Hayward & Son Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and 2,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at St-Bruno Shopping Center, Saint-Bruno-de-Montarville, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714960 Institutional Management and Supply Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Antoine Paré, lawyer, 695 Grosvenor, Westmount, Susan Alcock, 4311 Old Orchard, Apt.1607, and Charlotte-C.Roux, 3281 Forest Hill, Apt.9, the latter two secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes : To provide hospitals, hotels, convalescent and nursery homes and other institutions with services and facilities including laundry services, catering services and all other services used by such establishments, under the name of \"Institutional Management and Supply Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 715924 Koran Explorations Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Thomas Charles Hayhurst Baldwin, barrister, 10 Kimlock Crescent, Don Mills, Margaret Nancy Bannister, 58 Burgess Avenue, Jacqueline Kennedy, 1921A Queen Street East, Milliccnt Liburd, 100 Gamble Avenue, Apt.105, all three spinsters, and Rita Seifert, wife of Wolfgang Paul Seifert, 70 Delisle Avenue, Apt.304, the latter four legal secretaries, of Toronto, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals, under the name of \"Koran Explorations Limited », with a capital stock divided into 5,0U0,000 shares without par value. 1018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i' année, n\" 4 Le siège social de la compagnie est à 635 ouest, boulevard Dorchester, local 604, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715034 Kotai Music Inc.Musique Kotai inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Robert Nickford, gérant, 7682, rue Terbois, Saint-Léonard, Michelle Charbonneau, épouse d'André Charbonneau, 855, rue Dollard, app.3, Longueuil, et Helen Abaji, célibataire, 11907, James Morrice, Montréal, ces deux derniers secrétaires, pour les objets suivants: Exercer un commerce qui consiste à produire, manufacturer, euregistrer et vendre des disques pour phonographes, de la musique sur feuilles, instruments de musique et autres articles de nature similaire, sous le nom de «Kotai Music Inc.\u2014 Musique Kotai inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715217 H.A.Krauspc (1971) Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Samuel Shriar, 2445, Valade, Saint-Laurent, Maximilien Polak, 7897, chemin Wawell, Côte Saint-Luc, et Harvey Cooperstone, 1448, Beverley, Laval, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de « H.A.Krauspe (1971) Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $1(1 chacune el 20,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.4417S 715278 Lexington Enterprises Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour d'octobre 1971, consti- The head office of the company is at 635 Dorchester Boulevard West, Suite 604, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715034 Kotai Music Inc.Musique Kotai inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Robert Nickford, manager, 7682 Terbois Street, Saint-Léonard.Michelle Charbonneau.wife of André Charbonneau, 855 Dollard Street, Apt.3, Longueuil, and Helen Abaji, spinster, 11907 James Morrice, Montreal, the latter two secretaries, for the following purposes: To carry on the business of making, manufacturing, producting and selling of phonograph records, sheet music, musical instruments and other objects of a like nature, under the name of \"Kotai Music Inc.\u2014 Musique Kotai inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $10 each and 3,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Puilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715217 H.A.Krauspe (1971) Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 5th day of October, 1971, have been issued by the Minster of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Samuel Shriar, 2445 Valade, Saint-Laurent, Maximilien Polak, 7897 Wavell Road, Côte Saint-Luc, and Harvey Cooperstone, 1448 Beverley, Laval, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as builders and contractors, under the name of \"H.A.Kauspe (1971) Ltd.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philipf>e Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, \u201e Companies and Cooperatives.44178-o 7,5278 Lexington Enterprises Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Fmancial Institutions, Companies and Cooperatives, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.A 1019 tuant en corporation: Arthur I.Bronstcin, 24, place Holtham, Hampstead, Robert S.Litvack, 590, avenue Stanstead, Mont-Royal, et Sandor Klein, 6300, Lennox, app.807, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exploiter un commerce d'éditeurs et distributeurs de films et gérer des studios de vues animées, sous le nom de « Lexington Enterprises Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à 5480, rue Paré, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715615 incorporating: Arthur I.Bronstein, 24 Holtham Place, Hampstead, Robert S.Litvack, 590 Stanstead Avenue, Mount Royal, and Sandor Klein, 6300 Lennox, Apt.807, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of motion picture producers and distributors and to operate motion picture studios, under the name of \"Lexington Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of 840,000.divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at 5480 Pare Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 715615 Monoghan Mining Corporation (Québec) Limited (No personal liability) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: G.Harold Pickel, 47, Arlington, Westmount, Guy-E.Boisvert, 4976, Glen-cairn, Denyse Marcoux, 1488.Galt, tous deux de Montréal, tous trois avocats, et Ginette Doray, secrétaire, 1925, Labelle, Longueuil, ces deux dernières célibataires, pour les objets suivants: Faire des recherches et explorations aux fins de découvrir des mines et minerais, sous le nom de « Monoghan Mining Corporation (Québec) Limited » (No personal liability), avec un capital actions divisé en 5,000,000 a'actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715602 Optex Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de novembre 1971, constituant en corporation: Konstantin Grieb, opticien, 11964, Poincarré, Montréal-Nord, Walter Rimmler, entrepreneur, 631, Oliver Asselin, Laval, et Walter Wex, comptable, 1810, Connaught, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Manufacturer toutes sortes d'accessoires, de mécanismes, d'appareils, d'instruments et de matériel d'optique à l'usage des médecins, des dentistes, des opticiens, des hôpitaux et autres établissements du genre, en faire le commerce sous le nom de « Optex Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 15,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 2,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Monoghan Mining Corporation (Québec) Limited (No personal liability) Notice is given that under the provisions of the Mining Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: G.Harold Pickel, 47 Arlington, Westmount, Guy-E.Boisvert, 4976 Glencairn, Denyse Marcoux, 1488 Gait, both of Montreal, all three advocates, and Ginette Doray, secretary, 1925 Labelle, Longueuil, the latter two spinsters, for the following purposes: Prospect and explore the mines and minerals, under the name of \"Monoghan Mining Corporation (Québec) Limited\" (No personal liability), with a capital stock divided into 5,000,000 common shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715602 Optex Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Konstantin Grieb, optician, 11964 Poincarré, Montreal North, Walter Rimmler, contractor, 631 Oliver Asselin, Laval, and Walter Wcx.accountant, 1810 Connaught, Saint-Laurent, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of optical accessories, mechanisms, apparatus, instruments, supplies for use of doctors, dentists, opticians, hospitals and the like, under the name of \"Optex Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 15,000 common shares of the par value of $1 each and 2,500 preferred shares of the par value of $10 each. 1020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n\" 4 Le siège social de la compagnie est 3461, boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-1'hilippe Bouchard.44178 716006 The head office of the company is at 346J.St.Laurent Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 716006 Optimum Distribution Services Incorporated Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour d'août 1971, constituant en corporation : Adrien-R.Paquette, 212 Avenue Bloom-field, Outremont, Benoit Rivet, 335, rue Joliette, Longueuil, tous deux avocats, et Denise Paquette, secrétaire, célibataire, 9915, rue Esplanade, Montréal, pour les objets suivants: Agir à titre d'expéditeurs, d'agents en douanes et entreposeurs, d'agents de messagerie et d'entreposage, sous le nom de « Optimum Distribution Services Incorporated » avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair, 2,000 actions privilégiées, catégorie « A », de $10 chacune et 1,000 actions privilégiées, catégorie « B », de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 4415, rue Joseph Dubreuil, Lachine, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714472 Orvillc & Wilbur Fly Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Samuel H.Shriar, 2445, Valade, Saint-Laurent.Maximilien Polak, 7897 Wave 11 Road, Côte Saint-Luc, et Harvey Cooperstone, 1448 Beverly Crescent, Laval, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de promotion, exploitant et commercialisant l'aviation, incluant les services aériens et les services de nolisation d'avions de toutes sortes et de toutes descriptions, sous le nom de « Orville & Wilbur Fly Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714773 Pantazis, Assimakopoulos, Pantazis Insurance Agency Inc.L'agence d'assurance Pantazis, Assimakopoulos, Pantazis inc.Le minisrre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première Optimum Distribution Services Incorporated Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Adrien-R.Paquette, 212 Bloomfield Avenue, Outremont, Benoit Rivet, 335 Joliette Street, Longueuil, both Lawyers, and Denise Paquette, secretary, spinster, 9915 Esplanade Street, Montreal, for the following purposes: To act as forwarders, custom house brokers and warehousemen, storage and express agents, under the name of \"Optimum Distribution Services Incorporated\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without par value, 2,000 class \"A\" preferred shares of $10 each and 1,000 class \"B\" preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 4415 Joseph Dubreuil Street, Lachine, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 714472 Orville & Wilbur Fly Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Samuel H.Shriar, 2445 Valade, Saint-Laurent, Maximilien Polak, 7897 Wavell Road, Côte Saint-Luc, and Harvey Cooperstone.1448 Beverley Crescent, Laval, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business ot promoting, dealing in and merchandising flying, aerial and air charter services of all kinds and descriptions, under the name of \"Orville & Wilbur Fly Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714773 Pantazis, Assimakopoulos.Pantazis Insurance Agency Inc.L'agence d'assurance Pantazis, Assimakopoulos, Pantazis inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of October, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1021 partie de la Loi des compagnies, il à accordé des lettres patentes, en date du 6e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Apostolos Pantazis, agent d'assurance, Pierrette Mehalakopoulos, comptable, épouse dudit Apostolos Pantazis, tous deux de 20 Avenue Balzac, Candiac, et Aristomenis Assimakopoulos, courtier en assurance, 2842 Terrasse Louisbourg, Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie d'agents et de courtiers en assurances, sous le nom de « Pantazis, Assimakopoulos, Pantazis Insurance Agency Inc.\u2014 L'agence d'assurance Pantazis, Assimakopoulos, Pantazis inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Candiac, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions Ji/tujtcières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715332 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Apostolos Pantazis, insurance agent, Pierrette Mehalakopoulos, bookkeeper, wife of the said Apostolos Pantazis, both of 20 Balzac Avenue, Candiac, and Aristomenis Assimakopoulos, insurance broker, 2842 Louisbourg Terrace, Montreal, for the following pur]>oses: To carry on business as agents and insurance brokers, under the name of \"Pantazis, Assimakopoulos, Pantazis Insurance Agency Inc.\u2014 L'agence d'assurance Pantazis, Assimakopoulos, Pantazis inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Candiac, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715332 The Paper Place of Westmount Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Jacob Kattan, marchand, Bella Shiefledreen, professeur, épouse dudit Jacob Kattan, et Ainoin.-! Roubin, ménagère, épouse de Salman Kattan, tous trois de 1102, St-Aubin, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Faire le commerce du papier, produits d'icelui, papeterie, nouveautés, confiseries et menus articles, de toutes descriptions, sous le nom de « The Paper Place of Westmount Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de 81 chacune et 20.000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à 1, carré Westmount, (No 6-56), Westmount, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, .compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715618 Paramount Paper Products Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Nicholas Assaly, marchand, Doreen Assaly, ménagère, épouse dudit Nicholas Assaly, tous deux de 11814 rue Frigon, et Fred Assaly, gérant de bureau, 11772 rue Joseph Casavant, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer du papier et des produits du papier de toutes sortes, en faire le commerce, sous le nom de « Paramount Paper Products Ltd.», avec un capital total de $75,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 65,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 81 chacune.The Paper Place of Westmount Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacob Kattan, merchant, Bella Shiefledreen, teacher, wife of the said Jacob Kattan, and Amoma Roubin, housewife, wife of Salman Katta, all three of 1102 St-Aubin, Saint-Laurent, for the following purposes: To deal in paper, paper products, stationery, novelties, confectionery and smallwares of every description, under the name of \"The Paper Place of Westmount Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 20,000 common shares of 81 each and 20,000 preferred shares of 81 each.The head office of the company is at 1 Westmount Square (No.6-56), Westmount, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715618 Paramount Paper Products Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Nicholas Assaly, merchant, Doreen Assaly, housewife, wife of the said Nicholas Assaly, both of 11814 Frigon Street, and Fred Assaly, office manager, 11772 Joseph Casavant Street, all three of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in paper and paper products of all kinds, under the name of \"Paramount Paper Products Ltd.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 10,000 common shares at the par value of $1 each and 65,000 preferred shares at the par value of SI each. 1022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i' année, n° i Le siège social de la compagnie est à Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 715146 Peel Cycle Center Ltd.Centre du Cyclisme Pcel ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour d'août 1971, constituant en corporation: Frank Zimnicki, marchand, 3938 Avenue Carlton, Leonard Hambleton, gérant, 5366 Cumberland, tous deux de Montréal, et William McDonald, comptable, route rurale 2, Brownsburg, pour les objets suivants: Faire le commerce de tout ce qui est relié aux articles de sport et leurs accessoires, sous le nom de « Peel Cycle Center Ltd.\u2014 Centre du Cyclisme Peel ltée», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à 1018 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714080 Pejay Construction Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour d'août 1971, constituant en corporation: Edward J.Druker, 5763McMurray, Robert G.Wolfe, 5763 McAlear, tous deux avocats, de Côte Saint-Luc, Rachel R.Sands, veuve de Samuel Sands, 8659 Terrasse des Rapides, et Maureen Wright, célibataire, 0378 Bergevin, app.5, ces deux dernières secretaires, de Lasalle.pour les objets suivants: Exploiter les affaires d'une compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom de « Pejay Construction Inc.», avec un capital total de $40,000, divise en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1387 Avenue Allen, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714383 Pcreira International (Canada) Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour d'août 1971, constituant en corporation: Mortimer J.Constantino, avocat.The head office of the company is at Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 715146 Peel Cycle Center Ltd.Centre du Cyclisme Peel ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Frank Zimnicki, merchant, 3938 Carlton Avenue, Leonard Hambleton, manager, 5366 Cumberland, both of Montreal, and William MacDonald, accountant, R.R.#2, Brownsburg, for the following purposes: To deal in everything allied with sports equipment and accessories, under the name of \"Peel Cycle Center Ltd.\u2014 Centre du Cyclisme Peel ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1018 Sherbrooke Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutes, Companies and Cooperatives.44178-0 714080 Pejay Construction Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Edward J.Druker.5763 McMurray, Robert G.Wolfe, 5763 McAlear, both advocates, of Côte Saint-Luc, Rachel R.Sands, widow of Samuel Sands, 8659 des Rapides Terrace, and Maureen Wright, spinster, 0378 Bergevin, Apt.5, the latter two secretaries, of Lasalle, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, tinder the name of \"Pejay Construction Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 2.000 common shares of a par value of $10 each and 2,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at 1387 Allan Avenue, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714383 Pereira International (Canada) Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th dav of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Mortimer J.Constantine, advocate, 5080 Pou- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.4 1023 5080 Avenue Ponsard, Doreen Applebaum, secretaire, fille majeure, 1217 rue Drummond, app.44, tous deux de Montréal, et Victor N.Bradshaw, administrateur, 61 rue Emile Lavaltrie, pour les objets suivants: Etablir, entretenir, diriger et exploiter un commerce général, sous le nom de « Pereira International (Canada) Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 600 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie est 1117 ouest, rue Ste-Catherine, suite 505, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 3658-1971 Peters Mines Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour d'août 1971, constituant en corporation : I.David Fleming, 65 Belvedere Road, Westmount, Henri W.Laurier, 110 Brixton, Saint-Lambert, tous deux avocats, et Suzanne Vigeant, secrétaire, célibataire, 806 Avenue Rocklànd, Outremont, pour les objets suivants: Acquérir, posséder, louer, prospecter, ouvrir, explorer, développer, exploiter, améliorer, entretenir et diriger des mines, des terrains miniers et des gisements, sous le nom de « Peters Mines Ltd.», avec un capital divisé en 3,000,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est 1512 rue O'Brien, Chambly, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714134 Picken Service Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de septembre 1971, constituant en corporation: George Picken, mécanicien, Marguerite Picken, épouse dudit George Picken, tous deux de < 'raig Road, Richmond, et Sandra Picken, épouse de Brian Roberts, de Melbourne, ces deux dernières ménagères, pour les objets suivants: Exercer les affaires de garagistes et faire le commerce de voitures et véhicules ainsi que de toutes sortes de pièces et accessoires d'iceux, sous le nom de « Picken Service Inc.>', avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Richmond, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 714621 sard Avenue, Dorcen Applebaum, secretary, spinster, 1217.Drummond Street, Apt.44, both of Montreal, and Victor N.Bradshaw, executive, 61 Emile Street, Lavaltrie, for the following purposes: To establish, maintain, conduct, and carry on, a general merchandising business, under the name of \"Pereira International (Canada) Ltd.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 600 preferred shares of $50 each.The head office of the company is at 1117 St.Catherine Street West, Suite 505, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 3658-1971 Peters Mines Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: I.David Fleming, 65 Belvedere Road, West-mount, Henri W.Laurier, 110 Brixton, Saint-Lambert, both advocates, and Suzanne Vigeant, secretary, spinster, 806 Rockland Avenue, Outremont, for the following purposes: To acquire, own, lease, prospect for.open, explore, develop, work, improve, maintain and manage mines and mineral lands and deposits, under the name of \"Peters Mines Ltd.\", with a capital stock divided into 3,000,000 common shares without par value.The head office of the company is at 1512 O'Brien Street, Chambly, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M blister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714134 Picken Service Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of September, 1971, have been issued ny the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: George Picken, mechanic, Marguerite Picken, wife of the said George Picken, both of Craig Road.Richmond, and Sandra Picken.wife of Brian Roberts, Melbourne, the latter two housewives, for the following purposes: To carry on business as garage keepers and deal in conveyances and vehicles and the accessories and parts thereof of every kind, under the name of \"Picken Service Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Richmond, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178 o 714621-o 1024 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10k' année, n\" k Pincourt Restaurants Inc.Restaurants Pincourt inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de juin 1971, constituant en corporation: Seymour Machlovitch, 88 Summit Crescent, Westmount, Marvin Rosenhek, 335 Grenfell, Mont Royal, tous deux avocats, et Madeleine Lamothe, secrétaire, épouse de Nelson Jackson, 155 boulevard Deguire, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Exploiter le commerce de restaurant en bordure de la route dans toutes ses spécialités, sous le nom de « Pincourt Restaurants Inc.\u2014 Restaurants Pincourt inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Pincourt, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 3421-1971 Place Aylmer inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Jean-Yves (John) Payette, vendeur.1278 rue Boyer, Orleans, Marjorie Holmes, ménagère, épouse de John W.Johannson, 8 Avenue Whitehill, et Douglas Taylor Holmes, comptable agréé, 18 Langholm Crescent, ces deux derniers d'Ottawa, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'entrepreneurs en construction, sous le nom de « Place Aylmer inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 39,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Aylmer, district judiciaire de Hull.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714756 Les placements Bijar ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Irving I.Finkelberg, 35, Merton Crescent, Hampstead, Myer Stem, 5501, Adalbert, Côte Saint-Luc, tous deux avocats, et Racel Solomon, secrétaire, fille majeure, 4245, de la Peltrie, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom de « Les placements Bijar ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinuircs d'une voleur au pair de $1 Pincourt Restaurants Inc.Restaurants Pincourt inc.Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of June, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Seymour Machlovitch, 88 Summit Crescent, Westmount, Marvin Rosenhek, 335 Grenfell, Mount Royal, both advocates, and Madeleine Lamothe, secretary, wife of Nelson Jackson, 155 Deguire Boulevard, Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on the business in all of its branches of a drive-in restaurant, under the name of \"Pincourt Restaurants Inc.\u2014 Restaurants Pincourt inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Pincourt, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.44178-0 3421-1971 Place Aylmer inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Yves (John) Payette, salesman, 1278 Boyer Street, Orleans, Marjorie Holmes, housewife, wife of John W.Johannson, 8 Whitehill Avenue, and Douglas Taylor Holmes, chartered accountant, 18 Langholm Crescent, the latter two of Ottawa, for the following purposes: To carry on business as builders and contractors, under the name of \"Place Aylmer inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 39,000 preferred shares of $1 each.The head office of the companv is at Avlmcr, judicial district of Hull.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 7H756 Les placements Bijar ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Irving I.Finkelberg, 35 Merton Crescent, Hampstead, Myer Stern, 5501 Adalbert, Côte Saint-Luc, both advocates, and Racel Solomon, secretary, spinster, 4245 de la Peltric, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Les placements Bijar ltée\", with a total capital stock of $40,000 divided into 10,000 common shares of a par value of $1 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.lOi, No.4 1025 chacune el 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715930 Place St-Jean Discount Store Inc.Magasin d'escompte Place St-Jean inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Seymour Luterman, 26 Roxton Crescent, Montréal Ouest, Leslie I.Notkin, 3740 The Boulevard, Westmount, tous deux avocats, et Laura Firestone, secrétaire, épouse de Fred Firestone, 301 boulevard Deguire, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Exploiter le commerce de marchand général, sous le nom de « Place St-Jean Discount Store Inc.\u2014 Magasin d'escompte Place St-Jean inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de SI chacune.l.e siège social de la compagnie est à Montréa], district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714803 Preferred Leasebacks Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de novembre 1971, constituant en corporation: Murray Lapin, 167, chemin Edgehill, Westmount, Stephen Harper, 1212, ouest.Pine, tous deux avocats, et Joanne Doran, secrétaire, fille majeure, 666, ouest, Sherbrooke, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de « Preferred Leasebacks Limited », avec un capital divisé en 100,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 25,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715561 Provisions St-Benoit inc.St.Benoit Provisions Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Daniel Topalian, 4020 Place each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715930 Place St-Jcan Discount Store Inc.Magasin d'escompte Place St-Jean inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Seymour Luterman, 26 Roxton Crescent, Montreal West, Leslie I.Notkin, 3740 The Boulevard, Westmount, both advocates, and Laura Firestone, secretary, wife of Fred Firestone, 301, Deguire Boulevard, Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on the business of a general merchant, under the name of \"Place St-Jean Discount Store Inc.\u2014 Magasin d'escompte Place St-Jean inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe BoucnARD, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714803 Preferred Leasebacks Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Murray Lapin, 167 Edgehill Road, Westmount, Stephen Harper, 1212 Pine West, both advocates, and Joanne Doran, secretary, spinster, 666 Sherbrooke West, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Preferred Leasebacks Limited\", with a capital stock divided into 100,000 common shares without par value and 25,000 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutioits, Companies and Cooperatives.44178-o 715561 Provisions St-Benoit inc.St.Benoit Provisions Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Daniel Topalian, 4020 Place Jean-Masse, 1026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i' année, n° L Jean-Massé, Jean-Claude Topalian, Sahag Topalian, tous trois marchands, et Sirarpi Topalian, ménagère, épouse dudit Sahag Topalian, les trcis derniers de 308 ouest, rue Fleury, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de produits, marinades, conserves, condiments, sauces, épices, vivres et pro\\ isions, bière, boissens alcoolisées et non-alcoolisées, viandes, produits laitiers, céréales et autres produits de l'agriculture, sous le nom de « Provisions St-Benoit inc.\u2014 St.Benoit Provisions Inc.», avec un capital total de $40,000, divise en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Mcntréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 .714743 Q-M Excavation Ltd.Excavation Q-M ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour de septembre 1971, constituant en corporation : Pierre Campeau, administrateur, 8371 Curé Clermont, Anjou, Michelle Charbonneau, épouse de André Charbonneau, 855 Dollard, app.3, Longueuil, et Donna Sommer, fille majeure, 5750 Mapleridge, Côte Saint-Luc, ces deux dernières secrétaires, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'entrepreneurs en excavation et d'une compagnie de placement, sous le nom de « Q-M Excavation Ltd.\u2014 Excavation Q-M ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune et .3,900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 714944 Quadrant Construction Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de mai 1971, constituant en corporation: Murray B.Spiegel, 44 Roxborough, Westmount, David H.Solimcr, 5501 Adalbert, Côte Saint-Luc, tous deux avocats, et Francine Végiard, secrétaire, fille majeure, 135 est, Sherbrooke, Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie d'immeubles et de const ruction, sous le nom de « Quadrant Construction Ltd.», avec un capital total de $40.000, divisé en 30,000 actions ordinaires de $1 chacune et 10,000 actions privilégiées de SI chacune.Jean-Claude Topalian, Sahag Topalian, all three mer-chants, and Sirarpi Topalian, housewife, wife of the said Sahag Topalian, the latter three of 308 Fleury Street West, all four of Montreal, for the following purposes: To deal in all kinds of goods, pickles, condiments, preserves, sauces, spices, victuals and provisions, beer, soft and hard drinks, meats, dairy products, cereals and other agricultural products, under the name of \"Provisions St-Benoit inc.\u2014 St.Benoit Provisions Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common sfiares of SI each and 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714743 Q-M Excavation Ltd.Excavation Q-M ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Campeau, administrator, 8371 Curé Clermont, Anjou, Michelle Charbonneau, wife of André Charbonneau, 855 Dollard, Apt.3, Longueuil, and Donna Sommer, spinster, 5750 Mapleridge, Côte Saint-Luc, the latter two secretaries, for the following purposes : To carry on business as excavating contractors and act as an investment company, under the name of \"Q-M Excavation Ltd.\u2014 Excavation Q-M ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 3,900 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 ¦ 714944 Quadrant Construction Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of May, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Murray B.Spiegel, 44 Roxborough, Westmount, David H.Sohmer, 5501 Adalbert, Côte Saint-Luc, both advocates, and Francine Végiard, secretary, fille majeure, 135 Sherbrooke East, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Quadrant Construction Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 30,000 common shares of $1 each and 10,000 preferred shares of $1 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10L, No.U 1027 Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre adjoint des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.44178 2835-1971 Québec Hospital Supplies Ltd.Fournitures d'Hôpitaux Québec ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour d'août 1971, constituant en corporation: Fred Polansky, comptable, 415 St-Jacques, suite 202, Montréal, Joseph Tabah, 100 Côte Vertu, suite 909, et Richard Tabah, 150 Varry, ces deux derniers administrateurs, de Saint-Laurent, pour les objets suivants: Fabriquer et distribuer toutes sortes de produits et appareils qui seraient fournis aux hôpitaux et aux institutions, et agir comme agent distributeur de ces mêmes produits, sous le nom de « Québec Hospital Supplies Ltd.\u2014 Fournitures d'Hôpitaux Québec ltée », avec un capital total de 3205,000, divisé en 500 actions ordinaires de 810 chacune, 1,000 actions privilégiées, catégorie « A », de $100 chacune et 1,000 actions privilégiées, catégorie « 15 ' de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à 100 Côte Vertu, suite 909, Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714324 Quincaillerie J.R.Ravary ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour d'août 1971, constituant en corporation: Arthur Marcovitch, 5887 Centennial, Lawrence Glazer, 5753 Westminster, tous deux avocats, Jean-M.Guy, 4525 Harvard, tous trois de Montréal, et Meta Csirinyi, épouse de Julius Csirinyi, 2205 Depatie, Saint-Laurent, ces deux dernières secrétaires, pour les objets suivants: Exploiter le commerce de quincaillerie, sous le nom de \" Quincaillerie J.R.Ravary ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à 5066 rue Papineau, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714399 R.& A.Photo Vision Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Albert Jessop, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 2835-1971 Québec Hospital Supplies Ltd.Fournitures d'Hôpitaux Québec ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Fred Polansky, accountant, 415 St.James, Suite 202, Montreal, Joseph Tabah, 100 Côte Vertu, Suite 909, and Richard Tabah, 150 Varry, the latter two executives, of Saint-Laurent, for the following purposes: To manufacture, distribute, act as agent for any and all products and equipment that would be supplied to hospitals and institutions, under the name of \"Québec Hospital Supplies Ltd.\u2014 Fournitures d'Hôpitaux Québec ltée\", with a total capital stock of $205,000, divided into 500 common shares of $10 each, 1,000 class \"A\" preferred shares of $100 each and 1,000 class \"B\" preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 100 Côte Vertu, Suite 909, Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-PniLippE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714324 Quincaillerie J.R.Ravary ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Arthur Marcovitch, 5887 Centennial, Lawrence Glazer, 5753 Westminster, both advocates, Jean-M.Guy, 4525 Harvard, all three of Montreal, and Meta Csirinyi, wife of Julius Csirinyi, 2205 Depatie, Saint-Laurent, the latter two secretaries, for the following purposes: To carry on business as hardware merchants, under the name of \"Quincaillerie J.R.Ravary ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 5066 Papineau Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714399 R.& A.Photo Vision Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of July, 1971, have been issued by the Minister of Financial 1028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101} année, »\u2022 i patentes, en date du 28e jour de juillet 1971, constituant en corporation: Edward 3, Druker, 5763 Avenue McMurray, Robert G.Wolfe, 5763 Avenue McAlear, tous deux avocats de Côte Saint-Luc, et Rachel R.Sands, secrétaire, veuve de Samuel Sands, 8659 Terrasse des Rapides, Lasalle, pour les objets suivants: Exercer le commerce de photographes et de reproducteurs de photographies, sous le nom de « R.& A.Photo Vision Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à 6616 Fleet Road, Côte Saint-Luc, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 3981-1971 R & W Paper Converters Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Arthur I.Bronstein, 24 Holtham Place, Hampstcad, Normand Ainyot, 1445 Couvrette, Saint-Laurent, et Sandor 3, Klein, 6300 Lennox, app.807, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants : Fabriquer du papier et toutes sortes de produits du papier, en faire le commerce, sous le nom de « R & W Paper Converters Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 81 chacune et 3,900 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 2285 Ekers, suite 206, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 714990 Ramona Music School Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: William Fortis, administrateur, 116, rue Lapalme, Saint-Laurent, Adelio Bisecco 7230, L'Assomption, Saint-Léonard, et Spiro Athanasiou, 7022, Outremont, app.4, Montréal, ces deux derniers professeurs de musique, pour les objets suivants: Posséder, exploiter, gérer et administrer le commerce général d'une école de musique aux fins d'enseigner la musique et l'usage de tous instruments de musique, sous le nom de « Ramona Music School Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actionsordinaires d'une valeur au pair de 81 chacune et 390 actions privilégiées o'une valeur au pair de 8100 chacune.Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Edward J.Druker, 5763 McMurray Avenue, Robert G.Wolfe, 5763 McAlear Avenue, both advocates of Côte-Saint-Luc, and Rachel R.Sands, secretary, widow of Samuel Sands, 8659 Des Rapides Terrace, Lasalle, for the following purposes: To carry on business as photographers and reproducers of pictures, under the name of \"R.& A.Photo Vision Inc.\", with a total capital stock of 840.000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and 2,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at 6616 Fleet Road, Côte-Saint-Luc, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 3981-1971 R & W Paper Converters Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, incorporating: Arthur I.Bronstcin, 24 Holtham Place, Hampstead, Normand Amyot, 1445 Couvrette, Saint-Laurent, and Sandor J.Klein, 6300 Lennox, Apt.807 Montreal, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in paper and paper products of all kinds, under the name of \"R & W Paper Converters Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of SI each and 3,900 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company is at 2285 Ekers, Suite 206, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714990 Ramona Music School Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: William Fortis, executive, 116 Lapalme Street, Saint-Laurent, Adelio Bisecco, 7230 L'Assomption, Saint-Léonard, and Spiro Athanasiou, 7022 Outremont, Apt.4, Montreal, the latter two music teachers, for the following purposes: To own, operate, manage and generally deal in music school for the instruction and the use of all musical instruments, under the name of \"Ramona Music School Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1.000 common shares of the par value of $1 each and 390 preferred shares of the par value of 8100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.A 1029 Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715706 Rebico Investments Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour d'août 1971, constituant en corporation: C.Peter Turner, Brome, André Ba-chand, 146 rue Principale, tous deux avocats, et Nicole Deshaies, secrétaire, épouse de Serge Boucher, ces deux derniers de Cowansville, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie d'immeubles et de placement,.sous le nom de « Rebico Investments Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Cowansville, district judiciaire de Bedford.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714419 Rennat Enterprises Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de juillet 1971, constituant en corporation: Harvey Frumkin, 5618, Randall, Allen Feldman, 6405, Lennox, tous deux avocats, et Ann Palmer, secrétaire, fille majeure, 6321 Mazarin, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Fournir des centres récréatifs au public, et sans restreindre la portée de ce qui précède, exploiter des lieux de récréation et d'amusement, sous le nom de « Rennat Enterprises Limited», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de 81 chacune et 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard, 44178 714061 Restaurant Don Quichotte inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de juin 1971, constituant en corporation: Philippe Maroulis, 615 Avenue Cham-pagneur.Outremont, Demetrius Manolakos, 1321 ouest, rue Sherbrooke, app.D 41, Montréal, tous deux notai- The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715706 Rebico Investments Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: C.Peter Turner, Brome, André Bachand, 146 Main Street, both advocates, and Nicole Deshaies, secretary, wife of Serge Boucher, the latter two of Cowansville, for the following purposes: To carry on the business of a realty and investment company, under the name of \"Rebico Investments Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of the par value of $10 each and 2,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Cowansville.judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714419 Rennat Enterprises Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of July, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Harvey Frumkin, 5618 Randall, Allen Feldman, 6405 Lennox, both advocates, and Ann Palmer, secretary, spinster, 6321 Mazarin, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of furnishing amusement to the public and, without limiting the generality of the foregoing, to operate places of entertainment and amusement, under the name of \"Rennat Enterprises Limited\" with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 714061 Restaurant Don Quichotte inc.Notice is given that under l'art I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of June, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Philippe Maroulis, 615 Champagneur Avenue, Outremont, Demetrius Manolakos, 1321 Sherbrooke Street West, Apt.D-41, Montreal, both notaries, and 1030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101' année, n° i res, et Mary Manolakos, secrétaire, épouse de Themis-toclcs Kardàsh, 1476 Mercantile, Laval.p our les objets suivants: Exploiter un commerce de restaurant, sous le nom de « Restaurant Don Quichotte inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 30,000 actions ordinaires de $1 chacune et 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à 1050 boulevard Monseigneur Langlois, Saint-Timothée, district judiciaire de Beauharnois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-l'uiLiPPE Bouchard.44178 3457-1971 Restaurant Lacordaire ltée Lacordaire Restaurant Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour d'août 1971, constituant en corporation: Dennis Stathatos, Harry Georgiou, tous deux restaurateurs, de 7727 Avenue Birnam, et Lawrence Diner, avocat.4085 Avenue Harvard, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter le commerce de restaurants, sous le nom de « Restaurant Lacordaire ltée \u2014 Lacordaire Restaurant Ltd.», avec un capital total de $40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Léonard, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714508 Revcon Developments Limited Les aménagements Revcon limitée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13c jour de septembre 1971, constituant en corporation: Grant H.Day, 1455 ouest, rue Sherbrooke, app.315, Raymond LcMoyne, 4210 ouest, de Maisonneuve, et A.R.Dcane Nesbitt, 605 Habitat '67, Cité du Havre, tous trois avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom de « Revcon Developments Limited ¦\u2014 Les aménagements Revcon limitée », avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est 965 Côte de Liesse Road, Dorval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714887 Mary Manolakos, secretary, wife of Themistocles Kardash, 1476 Mercantile, Laval, for the following purposes: To carry on the business of a restaurant, under the name of \"Restaurant Don Quichotte inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 30,000 common shares of $1 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1050 Monseigneur Langlois, Boulevard, Saint-Timothée, judicial district of Beauharnois.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 3457-1971 Restaurant Lacordaire ltée Lacordaire Restaurant Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Dennis Stathatos, Harry Georgiou, both restaurateurs, of 7727 Birnam Avenue, and Lawrence Diner, advocate, 4085 Harvard Avenue, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of restaurants, under the name of \"Rc^aurant Lacordaire ltée \u2014 Lacordaire Restaurant Ltd.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Saint-Léonard, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714508 Revcon Developments Limited Les aménagements Revcon limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Grant H.Day, 1455 Sherbrooke Street West, Apt.315, Raymond LeMoyne, 4210 de Maisonneuve West, and A.R.Deane Nesbitt, 605 Habitat '67, Cité du Havre, all three advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Revcon Developments Limited \u2014 Les aménagements Revcon limitée\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without par value.The head office of the company is at 965 Côte de Liesse Road, Dorval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 714887 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 89, 1978, Vol.101, No.A 1031 Kii limill Enterprises Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Frank A.Bloomstone, notaire, 5465 Queen Mary Road, Monique Lapierre, épouse de Hervey Savoie, 11815 Place Monty, tous deux de Montréal, et Cécile Mauir, épouse de William Katz, 935 Effingham, Laval, ces deux dernières secrétaires, pour les objets suivants: Exercer les affaires de restaurateur et de pourvoyeur, sous le nom de « Richmill Enterprises Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 30,000 actions ordinaires de SI chacune et 10,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à 11845 rue de Poutrincourt, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714906 Robstan Enterprises Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour d'août 1971, constituant en corporation: Georges Stanley Groves, professeur, Lennoxville, Robert Francis John Barnctt, économiste, route rurale 5, Stanstead, et William Richard Henry Barnett, vendeur, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Exploiter le commerce d'aubergistes, de cabaretiers ou de restaurateurs, ou une agrégation d'iceux, sous le nom de « Robstan Enterprises Limited », avec un capital total de 850,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à 100 rue Queen, Lennoxville, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714305 S.C.S.Industries Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour d'août 1971, constituant en corporation: Julius Briskin, avocat, 134 Finchley Road, Hampstead, Jacqueline Soussan, épouse de Armand Soussan, 5216 Mountain Sights, Montréal, et Thérèse Perreault, fille majeure, 11986 Jubinville, Montréal Nord, ces deux dernières secrétaires, pour les objets suivants: Manufacturer du caoutchouc, du plastique, du verre, du métal et autres matières et substances de toutes espèces et de toutes descriptions, en faire le commerce, sous le nom de « S.C.S.Industries Corp.», avec un capital Richmill Enterprises Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of September, 1971, have been ssued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Frank A.Bloomstcne, notary, 5465 Queen Mary Road, Monique Lapierre, wife of Hervey Savoie, 11815 Place Monty, both of Montreal, and Cécile Mauir, wife of William Katz, 935 Effingham, Laval, the latter two secretaries, for the following purposes: To carry on the operation of a restaurant and food distribution, under the name of \"Richmill Enterprises Ltd.\", with a total capital stock cf $40,000, divided into 30,000 common shares of $1 each and 10,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 11845 de Poutrincourt Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714906 Robstan Enterprises Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Georges Stanley Groves, professor, Lennoxville, Robert Francis John Barnctt, economist, R.R.5, Stanstead, and William Richard Henry Barnett, salesman, Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on the business of inn-keepers, public house or restaurateurs or combination thereof, under the name of \"Robstan Enterprises Limited\", with a total capital stock of $50,000, divided into 200 common shares of a par value of $100 each and 300 preferred shares of a par value cf $100 each.The head office of the company is at 100 Queen Street, Lennoxville, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 714305 S.C.S.Industries Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Julius Briskin, advocate, 134 Finchley Road, Hampstead, Jacqueline Soussan, wife of Armand Soussan, 5216 Mountain Sights, Montreal, and Thérèse Perreault, spinster, 11986 Jubinville, Montreal North, the latter two secretaries, for the following purposes: To manufacture and deal in rubber, plastic, glass, metal and other material and substances of every kind and description, under the name of \"S.C.S.Industries Corp.\", with a total capital stock of $40,000, 1032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101' année, n° 4 total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à 907 Melville, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714402 S & M Restaurant & Hotel Equipment Co.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Sotirios Moutsios, commerçant, Pannagiota Bilsuuis, ménagère, épouse de Dinos Bitsa-nis, et -Joanna Moutsios, secrétaire, fille majeure, tous trois de 5390 Forester, Saint-Hubert, pour les objets suivants: Agir comme représentant et faire la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, et l'installation d'équipement et de mobiliers d'hôtels et de restaurants et autres accessoires semblables, sous le nom de « S & M Restaurant & Hotel Equipment Co.Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à 3155 rue Howard, Saint-Hubert, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies il coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714775 Salaberry Auto Body Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour d'août 1971, constituant en corporation: James O'Connor, administrateur, Marion Morris, ménagère, épouse dudit James O'Connor, tous deux de 28 Salaberry Sud, Châteauguay, et Paul Doray, comptable, 3822 boulevard Edouard Montpctit, Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et réparer toutes sortes d'automobiles, moteurs, engins, machines, carburateurs, accessoires et pièces et toutes sortes de mécanismes, instruments, ustensiles, appareils, lubrifiants, ciments, solutions et accessoires, en faire le commerce, sous le nom de «Salaberry Auto Body Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Lasalle, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714440 Scene Diversified Products Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 907 Melville, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714402 S & M Restaurant & Hotel Equipment Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 9th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Sotirios Moutsios, businessman, Pannagiota Bitsanis, housewife, wife of Dinos Bitsanis, and Joanna Moutsios, secretary, spinster, all three of 5390 Forester, Saint-Hubert, for the following purposes: Sale, importing, exporting, manufacture, installation and agency for restaurant and hotel equipment and funiture and similar accessories, under the name of \"S & M Restaurant & Hotel Equipment Co.Ltd.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 1,000 common shares of $10 each and 3.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 3155 Howard Street, Saint-Hubert, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minlster of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 714775 Salaberry Auto Body Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: James O'Connor, executive, Marion Morris, housewife, wife of the said James O'Connor, both of 28 Salaberry South.Châteauguay, and Paul Doray.accountant, 3822 Edouard Montpetit Boulevard, Montreal, for the following purposes: To manufacture, repair, deal in all kinds of automobiles, motors, engines, machines, carburettors, accessories and parts and all kinds of machinery, implements, ustensils, apparatus, lubricants, cements, solutions and appliances, under the name of \"Salaberry Auto Body Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Lasalle, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 71444o Scene Diversified Products Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1033 partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Morrie Neiss, pharmacien, Evelyn Siminovitch, ménagère, épouse dudit Morrie Neiss, tous deux de 4390 Isabella, Montréal, et Harold W.Ashenmil, avocat, 453 Mitchell, Mont Royal, pour les objets suivants: Fabriquer toutes sortes de préparations médicinales et pharmaceutiques, de médicaments brevetés, narcotiques, lotions, cosmétiques et tous autres produits semblables, en faire le commerce, sous le nom de 4 Scene Diversified Products Corp.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 4700 Avenue Prince of Wales, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715145 Seabro Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de septembre 1971, autorisant la fusion de la compagnie « Segal Limited » et de la compagnie « Seabro Bldg.Ltd.», toutes deux constituées en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes respectivement datées du 28 novembre 1952 et du 19 novembre 1959, pour les objets suivants: Acquérir, acheter, administrer, gérer, réparer, louer et construire des immeubles et biens immobiliers, sous le nom de « Seabro Corporation », avec un capital total de $110,000 divisé en 11,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715076 Sécurité Ito inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de juin 1971, constituant en corporation: Lise-G.Babin, secrétaire, fille majeure, 9688, 28e Avenue, Roland-G.Chauvin, 11530 Dépatie, Louis-S.Bonin, 1587 Terrasse Garnier, tous trois de Montréal, Paul-E.Dion, 279 Hubert, Greenfield Park, et George Blake Knox, 104 Ferdinand, Châteauguay, ces quatre derniers avocats, pour les objets suivants: Exploiter un service de personnel et de sécurité pour les individus, les entreprises et les compagnies de toutes sortes, sous le nom de « Sécurité Ito inc.», avec un capital divisé en 10,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.September, 1971, bave been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Morrie Neiss, pharmacist, Evelyn Siminovitch, housewife, wife of the said Morrie Neiss, both of 4390 Isabella, Montreal, and Harold W.Ashenmil, advocate, 453 Mitchell, Mount Royal, for the following purposes: To manufacture and deal in all types of medicinal and pharmaceutical preparations, patent medicines, drugs, lotions, beauty aids and related supplies, under the name of \"Scene Diversified Products Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 4700 Prince of Wales Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 7.15145 Seabro Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, dated the 23rd day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, authorizing the amalgamation of \"Segal Limited\", and \"Seabro Bldg.Ltd.\", both incorporated under the said Part I of the Companies Act, by letters patent dated, respectively, November 28, 1952, and November 19, 1959, for the following purposes: To acquire, purchase, administer, operate, repair, lease and construct real estate and immoveables, under the name of \"Seabro Corporation\", with a total capital stock of $110,000 divided into 11,000 common shares of the par value of $10 each.The head office of the new company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 715076 Sécurité Ito inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letteis patent, bearing date the 25th day of June, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Lisc-G.Babin, secretary, fille majeure, 9688, 28th Avenue, Roland-G.Chauvin, 11530 Dépatie, Louis-S.Bonin, 1587 Terrasse Garnier, all three of Montreal, Paul-E.Dion.279 Hubert, Greenfield Park, and George Blake Knox, 104'Ferdinand, Châteauguay, the latter four advocates, for the following purposes: To operate a personnel and security service for individuals, firms and corporations of all kinds, under the name of \"Sécurité Ito inc.\", with a capital stock divided into 10,000 common shares without par value and 3.000 preferred shares of the par value of $10 each. 1034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-m inislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 3445-1971 Sergio Realties Inc, Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date_du 6e jour de juin 1971, constituant en corporation: Emilie St-Onge, propriétaire foncière, épouse de Roméo Béliveau, 449 Clermont, Seymour Machlovitch, avocat, 88 Summit Crescent, tous deux de Westmount, et Madeleine Lamothe, secrétaire, épouse de Nelson Jackson, 155 Deguire, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom de « Sergio Realties Inc.avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 2962-1971 Seton Development Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Michelle Charbonneau, épouse de André Charbonneau, 855 Dollard, app.3, Longueuil, Donna Sommer, fille majeure, 5750 Maple-ridge, toutes deux secrétaires, et Stephen Marcovitch, avocat, 5724 Eldridge, ces deux derniers de Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de placement, sous le nom de « Seton Development Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 81 chacune et 3,900 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714945 S.Greenberg & Assoc.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donDe avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Ruth K.Day, épouse de Edward Quigg, 9811 boulevard Lasalle, app.120, Lasalle, Bessie Plotnick, épouse de Dave Peters, 3805 Dupuis, app.4, The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 3445-1971 Sergio Realties Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of June, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Emilie St-Onge, landowner, wife of Roméo Béliveau, 449 Clermont, Seymour Machlovitch, advocate, 88 Summit Crescent, both of Westmount, and Madeleine Lamothe, secretary, wife of Nelson Jackson, 155 Deguire, Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Sergio Realties Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and 30,000 preferred shares of 81 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-PniLiPPE Bouchard, Deputy Minister of Financial histitutions.Companies and Cooperatives.44178-0 2962-1971 Seton Development Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michelle Charbonneau, wife of André Charbonneau, 855 Dollard, Apt.3, Longueuil, Donna Sommer, spinster, 5750 Mapleridge, both secretaries, and Stephen Marcovitch, advocate, 5724 Eldridge, the latter two of Côte Saint-Luc, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Seton Development Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 81 each and 3,900 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714945 S.Greenberg & Assoc.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Ruth K.Day, wife of Edward Quigg, 9811 Lasalle Boulevard, #120, Lasalle, Bessie Plotnick, wife of Dave Peters, 3805 Dupuis, #4, Montreal, both secre- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 39, 1973, Vol.101, No.I Montréal, toutes deux secrétaires, et Tibor J.Lebovics, avocat, 5791 Trinity, Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de courtiers et d'agents d'assurance, sous le nom de « S.Greenberg & Assoc.Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715331 Sherelco Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour d'août 1971, constituant en corporation: John York, gérant, René Monty, avocat, tous deux de North Hatley, et Guy Landry, étudiant en droit, 2654 ouest, rue King, Sherbrooke, pour les objets suivants: Exploiter une entreprise d'électriciens et faire le commerce de générateurs électriques, de moteurs électriques, d'appareils électriques et accessoires de toutes descriptions, sous le nom de « Sherelco Inc.», avec un capital total de $150,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $10 chacune et 5,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à 1635 rue Denault, Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714292 Shuchat Franchises (Drummondville) Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour d'août 1971, constituant en corporation: Earl S.Cohen, 4919 Montclair, Douglas L.Pascal, 5392 Prince of Wales, et Yves L'Anglais, 5820, Place Decelles, tous trois avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Posséder, tenir, exploiter, gérer et diriger à son propre compte ou pour le compte des autres, des restaurants, restaurants en bordure de route, cafés, dinettes, casse-croûtes, salles à dîner, cafeterias, et autres établissements du même genre, sous le nom de « Shuchat Franchises (Drummondville) Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à 5606 avenue Pinedale, Côte Saint-Luc, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714270 1035 taries, and Tibor J.Lebovics, advocate, 5791 Trinity, Côte Saint-Luc, tor the following purposes: To carry on business as agents and insurance brokers, under the name of \"S.Greenberg & Assoc.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715331 Sherelco Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of August, 1971.have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: John York, manager, René Monty, advocate, both of North Hatley, and Guy Landry, law-student, 2654 King Street West, Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business as electricians and deal in electric-power plants, electric motors, electric appliances and accessories of every description, under the name of \"Sherelco Inc.\", with a total capital stock of $150.000, divided into 10,000 common shares of $10 each and 5,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1635 Denault Street, Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Phimppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714292 Shuchat Franchises (DrummondviUe) Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Earl S.Cohen, 4919 Montclair, Douglas L.Pascal, 5392 Prince of Wales, and Yves L'Anglais, 5820 Decelles Place, all three advocates, of Montreal, for the following purposes: To own, maintain, operate, manage and conduct for its account or for the account of others, drive in restaurants, restaurants, cafés, lunch-rocms, snack bars, dining rooms, cafeterias and similar types of establishments, under the name of \"Shuchat Franchises (Drummondville) Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 5606 Pinedale Avenue, Cote Saint-Luc, judicial district of Montreal.Lb-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institution», Companies and Cooperatives.44178-o 714270 1036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 39 janvier 1972, 104' année, n° 4 South Eastern Gas & Oil Ltd.(No personal liability) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour d'octobre 1971, constituant en corporation : G.Harold Pickel, 47, Arlington, Westmount, Guy-E.Boisvert, 4976, Glencairn, tous deux avocats, et Denyse Marcoux, secrétaire, célibataire, 1488, Galt, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et explorations aux fins de découvrir des mines et minerais, sous le nom de « South Eastern Gas & Oil Ltd.» (No personal liability), avec un capital actions divisé en 5,000,000 d'actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715455 Vadar Realties Inc.Les immeubles Vadar inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Richard S.Gottlieb, 5626, Eldridge, Côte Saint-Luc, Robert AV.Agard, 3460, Durocher, et Pierre Phaneuf, 5835, de Terrebonne, ces deux derniers de Montréal, tous trois avocats, poulies objets suivants : Exercer les affaires d'une compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom de « Vadar Realties Inc.\u2014 Les immeubles Vadar inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715700 Variety Discount Fabrics Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour d'août 1971, constituant en corporation: Nico Van Gelder, médecin, Louise Van Gelder, épouse dudit Nico Van Gelder, tous deux de 1425, Kingsley, Dorval, et Germaine Lebeuf, épouse de Yvon Lebeuf, 5200 Connaught, Montréal, ces deux dernières ménagères, pour les objets suivants: Manufacturer des marchandises, articles et effets de toutes sortes de description, en faire le commerce, sous le nom de « Variety Discount Fabrics Inc.», South Eastern Gas & Oil Ltd.(No personal liability) Notice is given that under the provisions of the Mining Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: G.Harold Pickel, 47 Arlington, Westmount, Guy-E.Boisvert, 4976 Glencairn, both advocates, and Denyse Marcoux, secretary, spinster, 14S8 Gait, the latter two of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals, under the name of \"South Eastern Gas & Oil Ltd.\" (No personal liability), with a capital stock divided into 5,000,000 common shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715455 Vadar Realties Inc.Les immeubles Vadar inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of October, 1971.have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Richard S.Gottlieb, 5626 Eldridge, Côte Saint-Luc, Robert W.Agard, 3460 Durocher, and Pierre Phaneuf, 5835 de Terrebonne, the latter two of Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Vadar Realties Inc.\u2014 Les immeubles Vadar inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 20,000 common shares of 81 each and 20,000 preferred shares of 81 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44l78-o .715700 Variety Discount Fabrics Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Nico Van Gelber, physician, Louise Van Gelder, wife of the said Nico Van Gelder, both of 1425 Kingsley, Dorval, and Germaine Lebeuf, wife of Yvon Lebeuf.5200 Connaught, Montreal, the latter two housewives, for the following purposes: To manufacture and deal in goods, wares and merchandise of every kind and nature, under the name of \"Variety Discount Fabrics Inc.\", with a total capital QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.i 1037 avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est au 423, rue Mayor, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Ls-Philippe Bouchard.44178 714674 Viauville Tire Ltd.Le ministre des institutions finajicières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de septembre 1971, constituant en corporation: Eddy John Assaf, manufacturier, Filoména Assaf, commis, épouse dudit Eddy John Assaf, tous deux de 10451 des Récollets, et Jean-Marie Lavoie, vendeur, 10452, des Récollets, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce de vente et achat de pneus et accessoires d'automobiles, sous le nom de « Viauville Tire Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est au 4907 est, rue Ste-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714968 W.H.H.Investments Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: I.David Fleming, 65, chemin Belvédère, Joseph Di Clementi, 4300 boulevard de Maison-neuve, Montréal, et Henri-W.Laurier, 110, Brixton, Saint-Lambert, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer des affaires à titre d'actionnaires, capitalistes, financiers, courtiers et agents, sous le nom de « W.H.H.Investments Ltd.», avec un capital-actions divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est au 620 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715262 Warshaw Wholesale Inc.stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of $1 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 423 Mayor Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714674 Viauville Tire Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 20th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Eddy John Assaf, manufacturer, Filoména Assaf, clerk, wife of the said Eddy John Assaf, both of 10451 des Récollets, and Jean-Marie Lavoie, salesman, 10453 des Récollets, all three of Montreal North, for the following purposes: To carry on the business of buying and selling tires and auto accessories, under the name of \"Viauville Tire Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 4907 St.Catherine Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714968 W.H.H.Investments Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: I.David Fleming, 65 Belvedere Road, Westmount, Joseph Di Clementi, 4300 de Maisonneuve Boulevard, Montreal, and Henri-W.Laurier, 110 Brixton, Saint-Lambert, all three advocates, for the following purposes : To carry on business as investors, capitalists, financiers, brokers and agents, under the name of \"W.H.H.Investments Ltd.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without par value.The head office of the company is at 620 St.James Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715262 Warshaw Wholesale Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de September 1971, consti- Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 13th clay of September, 1971, have been issued by the Minister o Financial Institutions, Companies and Cooperatives- 1038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10k' année, n° l tuant en corporation: Brahm M.Gelfand, avocat, 5140, Mayfair, Penny Coley, 10250, Bois de Boulogne, app.104, et Margaret Tucker, 10250, Bois de Boulogne, app.101A, ces deux dernières secrétaires, célibataires, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir, construire et gérer des entrepôts, magasins et boutiques et faire le commerce d'épiceries et de toutes sortes de marchandises, articles et effets sous le nom de « Warshaw Wholesale Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est au 3863, boulevard St-Laurcnt, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714851 West-Island Estates Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour d'août 1971, constituant en corporation: Shirley Patenaude, 1854, Patricia, app.3, Rickie Blitstein, 271, Willowdale, toutes deux filles majeures, et Francine Barnes, épouse de Maurice Barnes, 1270, Qucnneville, app.218, toute trois secrétaires, pour les objets suivants: Agir à titre de consultants en immeuble, mise en valeur et construction, sous le nom de « West-Island Estates Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 20,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.\" Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714119 incorporating: Brahm M.Gelfand, advocate, 5140 Mayfair, Penny Coley, 102,50 Bois de Boulogne, Apt.104, and Margaret Tucker, 10250 Bois de Boulogne, Apt.101 A, the latter two secretaries, spinsters, all three of Montreal, for the following purposes: To acquire, construct and operate warehouses, stores and shops and deal in groceries and all kinds and classes of goods, wares and merchandise, under the name of \"Warshaw Wholesale Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 3863 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 714851 West-Island Estates Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Shirley Patenaude, 1854 Patricia, Apt.3, Rickie Blitstein, 271 Willowdale, both filles majeures, and Francinc Barnes, wife of Maurice Barnes, 1270 Quenne-ville.Apt.218, all three secretaries, of Montreal, for the following purposes: To act as consultants in real estate, development and construction matters, under the name of \"West-Island Estates Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 20,000 common shares of a par value of $1 each and 20,000 preferred shares of-a par value of SI each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 714119 Brendan Wood & Associates (Québec) Ltd.Brendan Wood & associés (Québec) ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Louis-Bruno Gascon, avocat, 5374 Decelles, Eric Boulva, 885 Gray-Circlc, tous deux de Montréal, et Herb Pinchuck, 2040 Veniard, Saint-Laurent, ces deux derniers étudiants, pour les objets suivants: Exercer les affaires à titre de conseillers en administration, sous le nom de « Brendan Wood & Associates (Québec) Ltd.\u2014 Brendan Wood & associés (Québec) ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Brendan Wood & Associates (Québec) Ltd.Brendan Wood & associés (Québec) ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Louis-Bruno Gascon, advocate, 5374 Decelles, Eric Boulva, 885 Gray-Circle, both of Montreal, and Herb Pinchuck, 2040 Veniard, Saint-Laurent, the latter two students, for the following purposes: To carry on business as management consultants under the name of \"Brendan Wood & Associates (Québec) Ltd.\u2014 Brendan Wood & associés (Québec) ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of the par value of $1 each and 20,000 preferred shares of the par value of $1 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 Le siège social de la compagnie est 2015 rue Drum-mond, suite 1008, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715308 Zasarsky's Restaurant Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour d'octobre 1971, constituant en corporation: Doreen Manning, secrétaire, épouse de Claud Manning, 712, 31e Avenue, Lachine, Lawrence L.Fligel, 4875 Bourret, et Jules Leavitt, 4001 Kinders-ley, ces deux derniers avocats, de Montréal, pour les objets suivants : Exploiter un commerce de restaurant, sous le nom de « Zasarsky's Restaurant Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à 9500 Meilleur, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralives, Ls-Philippe Bouchard.44178 715432 Lettres patentes supplémentaires African Safari Park (Québec) Inc.Parc Safari Africain (Québec) inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour d'octobre 1971, à la compagnie « African Safari Park (Québec) Inc.\u2014 Parc Safari Africain (Québec) inc.», augmentant son capital par la création de 160,000 actions ordinaires sans valeur au pair; l'estimation globale de l'émission des 160,000 actions ordinaires ne devra pas excéder la somme de $160,000 en montant ou en valeur.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralives, Ls-Philippe Bouchard.44178 714140 Air Ste-Agathe inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 27e jour de septembre 1971, à la compagnie « Services Aériens de Sainte-Agathe-des-Monts inc.\u2014 Sainte-Agathe-des-Monts Air Services Inc.», constituée par lettres patentes en date 1039 The head office of the company is at 2015 Drummond Street, suite 1008, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 715308 Zasarsky's Restaurant Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Doreen Manning, secretary, wife of Claud Manning, 712, 31st Avenue, Lachine, Lawrence L.Fligel, 4875 Bourret, and Jules Leavitt, 4001 Kindersley, the latter two advocates, of Montreal, for the following purposes: \u2022 To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Zasarsky's Restaurant Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 9500 Meilleur, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minisler of Financial Institutions, Companies and Cooperati ves.44178-0 715432 Supplementary Letters Patent African Safari Park (Québec) Inc.Pare Safari Africain (Québec) inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"African Safari Park (Québec) Inc.\u2014 Pare Safari Africain (Québec) inc.\", increasing its capital by the creation of 160,000 common shares without par value; the aggregate consideration for the issue of the said 160,000 common shares shall not exceed in amount or value the sum of $160,000.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 714140 Air Ste-Agathe inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters' patent, bearing date the 27th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Services Aériens de Sainte-Agathe-des-Monts inc.\u2014 Sainte-Agathe-des-Monts Air Services Inc.\", incorporated by letters patent dated 11th day of 1040 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1912, 104' année, n\" 4 du lie jour de décembre 1962, changeant son nom en celui de « Air Ste-Agathe inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 14740-62 Air-Vision Industries Inc.Les Industries Air-Vision inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 10e jour de novembre 1971, à la compagnie « Air-Vision Industries Inc.\u2014 Les Industries Air-Vision inc.», augmentant son capital de $40.000 à $140.000 par la création de 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair.de $10 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 .5636-68 December, 1962.changing its name to that of \"Air Ste-Agathe inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 14740-62 Air-Vision Industries Inc.Les Industries Air-Vision inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 10th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Air-Vision Industries Inc.\u2014 Les Industries Air-Vision inc.\", increasing its capital from $40.000 to $140.000 by the creation of 10,000 common shares of the par value of $10 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 5636-68 Beam, an! Shopping Centres Ltd.Les Centres d'Achats Beauward ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 26e jour de juillet 1971, à la compagnie « Place St.Eustache ltée », constituée par lettres patentes en date du 20e jour de juillet 1960, 1° changeant son nom en celui de « Beauward Shopping Centres Ltd.\u2014 Les Centres d'Achats Beauward ltée»; 2° modifiant ses pouvoirs; 3° diminuant son capital de 810,000 à $1,000 par l'annulation de 9,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune; 4° augmentant son capital de $1,000 à $100,000 par la création de 9,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 9,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralives, Ls-Philippe Bouchard.44178 12983-60 Blue Star Trading Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 30c jour d'août 1971, à la compagnie « Blue Star Trading Ltd.», 1° augmentant son capital de $40,000 à $80,000 par la création de 400 actions privilégiées d'une valeur au pair $100 chacune; 2° modifiant les privilèges et restrictions attachés à ses actions privilégiées.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 3203-52 Beauward Shopping Centres Ltd.Les Centres d'Achats Beauward liée Notice is given that, under Part I oi the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of July, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Place St.Eustache ltée\", incorporated by letters patent dated 20th day of July, 1960, 1.changing its name to that of \"Beauward Shopping Centres Ltd.\u2014 Les Centres d'Achats Beauward ltée\"; 2.modifying its powers; 3.reducing its capital from 810,000 to 81,000 by the cancellation ot 9,000 preferred shares of the par value of $1 each; 4.increasing its capital from 81,000 to 8100,000 by the creation of 9,000 common shares of the par value of $1 each and 9,000 preferred shares of the par value of $10 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 12983-60 Blue Star Trading Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of August, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Blue Star Trading Ltd.\", 1.increasing its capital from $40,000 to $80,000 by the creation of 400 preferred shares of the par value of $100 each; 2.modifying the privileges and restrictions attached' to its preferred shares.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 3203-52 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.k 1041 J.Broderick Service Ltd.Service J.Broderick ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 23e jour de novembre 1971, à la compagnie « J.Broderick Service (1965) Limited », constituée par lettres patentes en date du 24e jour de septembre 1965, changeant son nom en celui de « J.Broderick Service Ltd.\u2014 Service J.Broderick ltée ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 4252-65 Club Social de ViUc-Émard Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 16e jour de septembre 1971, à la corporation « Club Social de Ville-Émard », 1° modifiant ses pouvoirs; 2° augmentant le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation à 850,000.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 13147-61 J.Broderick Service Ltd.Service J.Broderick ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 23rd day of November, 1971, have been issued by tlie Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"J.Broderick Service (1965) Limited\", incorporated by letters patent dated 24th day of September, 1965, changing its name to that of \"J.Broderick Service Ltd.\u2014 Service J.Broderick ltée\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 4252-65 Club Social de ViUe-Émard Notice is given that, under Part III of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Club Social de Ville-Emard\", 1.modifying its powers; 2° increasing the amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited to 850,000.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 13147-61 Consolidated-Bathurst Pulp and Paper Limited Pâtes et Papiers Consolidated-Bathurst limitée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 18e jour de novembre 1971, à la compagnie « Consolidated Peribonka Inc.», constituée par lettres patentes en date du 2e jour d'août 1965, 1° changeant son nom en celui de « Consolidated-Bathurst Pulp and Paper Limited \u2014 Pâtes et Papiers Consolidated-Bathurst limitée » ; 2° modifiant les dispositions de ses lettres patentes.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 3424-65 Dixville Home Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, supplémentaires en date du 26e jour de novembre 1971, à la corporation « Dixville Home Inc.», augmentant le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation de 8200,000 à 81,000,000.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 2441-63 Consolidated-Bathurst Pulp and Paper Limited Pâtes et Papiers Consolidated-Bathurst limitée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 18th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Consolidated Peribonka Inc.\", incorporated by letters patent dated 2nd day of August, 1965, 1.changing its name to that of \"Consolidated-Bathurst Pulp and Paper Limited \u2014 Pâtes et Papiers Consolidated-Bathurst limitée\"; 2.modifying the provisions of its letters patent.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 3424-65 Dixville Home Inc.Notice is given that, under Part III of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Dixville Home Inc.\", increasing the amount of immoveable property which may be owned or held by the corporation from 8200,000 to 81,000,000.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 2441-63 1042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10V année, n° i E-Z Insurance Premium Corporation La Corporation de Prime* d'Assurance E-Z Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 3e jour de septembre 1971, à la compagnie « E-Z Insurance Premium Corporation \u2014 La Corporation de Primes d'Assurance E-Z », augmentant son capital de $40,000 à $100,000 par la création de 6,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune, les plaçant au même rang que les actions privilégiées déjà existantes.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 4025-69 Firm Root Investment Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 28e jour de juillet 1971, à la compagnie « Firm Root Investment Corp.», diminuant son capital de $10,000 à $9,000 par l'annulation de 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 10948-59 General Customs Brokers Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 16c jour de septembre 1971, à la compagnie « Great West Fur Inc.», constituée par lettres patentes en date du 14e jour de juillet 1961, 1° changeant son nom en celui de « General Customs Brokers Inc.»; 2° modifiant ses pouvoirs.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 13621-61 Gerbro Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 27c jour d'octobre 1971, à la compagnie « Gerbro Corp.», modifiant les conditions attachées à ses actions privilégiées antérieures.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralives, Ls-Philippe Bouchard.44178 10839-60 E-Z Insurance Premium Corporation La Corporation de Primes d'Assurance E-Z Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 3rd day of September, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"E-Z Insurance Premium Corporation\u2014 La Corporation de Primes d'Assurance E.Z\", increasing its capital from $40,000 to $100.000 by the creation of 6,000 preferred shares of the par value of $10 each, ranking pari passu in all respects with the existing preferred shares.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Instittitious, Companies and Cooperatives.44178-o 4025-09 Firm Root Investment Corp.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of July.1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Firm Root Investment Corp.\", reducing its capital from $10.000 to $9,000 by the cancellation of 1,000 preferred shares of the par value of $1 each.Ls-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 10948-59 General Customs Brokers Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of September, 1971.have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Great West Fur Inc.\", incorporated by letters patent dated 14th day of July, 1961, 1.changing its name to that of \"General Customs Brokers Inc.\"; 2.modifying its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 13621-61 Gerbro Corp.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 27th day of October, 1971, have been issueil by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Gerbro Corp.\", modifying the conditions pertaining to the prior preferred shares.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Fiiutncial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 10839-60 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1043 Gervais Chaise & Table ltée Gervais Chair & Table Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour d'octobre 1971, à la compagnie « Gervais Chaise & Table ltée \u2014 Gervais Chair & Table Ltd.», 1° diminuant son capital de 3125,000 à $102,900 par l'annulation de 2,210 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune; 2° convertissant 7,790 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune en 7,790 actions ordinaires sans valeur au pair; 3° augmentant son capital par la création de 1,710 actions ordinaires sans valeur au pair; l'estimation globale pour l'émission desdites 10,000 actions ordinaires sans valeur au pair ne devra pas dépasser $102,900 en montant ou en valeur.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 5315-49 Graham Secretarial College Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 12e jour d'octobre 1971, à la compagnie « Graham's Business College Inc.», constituée par lettres patentes en date du 19e jour de décembre 1971, changeant son nom en celui de « (j ran ham Secretarial College Inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 13876-60 Greek Social Centre Inc.I.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 25e jour d'octobre 1971, à la corporation « Greek Social Centre Inc.», modifiant ses pouvoirs.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 5754-70 Grecnshields Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 28e jour de mai 1971, à la compagnie « Greenshields Ltd.», augmentant son capital par la création de 13 actions catégorie « B » sans valeur au pair et 2,000,000 d'actions privilégiées deuxième catégorie d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 12510-61 Gervais Chaise & Table ltée Gervais Chair & Table Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions,.Companies and Cooperatives to \"Gervais Chaise & Table ltée \u2014 Gervais Chair & Table Ltd.\", 1.reducing its capital from $125,000 to $102,900 by the cancellation of 2,210 preferred shares of the par value of $10 each; 2.converting 7,790 preferred shares of the par value of $10 each into 7,790 common shares without par value; 3.increasing its capital by the creation of 1,710 common shares without par value; the aggregate consideration for the issue of the said 10,000 common shares without par value shall not exceed in amount or value the sum of $102,900.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 5315-49 Graham Secretarial CoUege Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 12th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Graham's Business College Inc.\", incorporated by letters patent dated 19th day of December, 1971, changing its name to that of \"Graham Secretarial College Inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 13876-60 Greek Social Centre Inc.Notice is given that, under Part III of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Greek Social Centre Inc.\", modifying its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 5754-70 Greenshields Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of May, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Greenshields Ltd.\", increasing its capital by the creation of 13 class \"B\" shares without par value and 2,000,000 second preferred shares of the par value of $1 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 12510-61 1044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 39 janvier 1973, 104' année, n\" 4 Halliday, Dubé Lumber Company Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 25e jour de novembre 1971, à la compagnie « Halliday, Dubé Lumber Company », diminuant son capital de $249,000 à $80,130 par l'annulation de 168,870 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-ministre des institutioitsfiiiancièrcs, compagnies et coopératives, Ls-PulLIPPE bouchard.44178 1609-23 Mr Hanger (Québec) Inc.Le luiuistre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 25e jour d'octobre 1971, à la compagnie « Mr Hanger (Québec) Inc.», 1° subdivisant 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacun et 390 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune en 39,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune; 2° augmentant son capital de $49,000 à $250,000 par la création de 25,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 176,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 1373-66 Ken llaiinn Associates Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 16e jour de novembre 1971, à la compagnie « Economist Publications & Color Service Limited », constituée par lettres patentes en date du 8e jour de juillet 1968, changeant son nom en celui de « Ken Hatton Associates Limited ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 2832-68 Hawco Construction Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 12e jour de novembre 1971, à la compagnie « Hawco Construction Ltd.», étendant ses pouvoirs.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 13470-59 Halliday, Dubé Lumber Company Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Halliday, Dubé Lumber Company\", reducing its capital from $249,000 to $S0,130 by the cancellation of 168,870 preferred shares of the par value of $1 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 1609-23 Mr Hanger (Québec) Inc.Notice is given that, under Part I of the Coinpauies Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Mr Hanger (Québec) Inc.\", 1.subdividing 100 common shares of the par value of $100 each into 10,000 common shares of the par value of $1 each and 390 preferred shares of the par value of $100 each into 39,000 preferred shares of the par value of $1 each; 2.increasing its capital from $49,000 to $250,000 by the creation of 25.000 common shares of the par value of $1 each and 176,000 preferred shares of the par value of $1 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 1373-66 Ken Hatton Associates Limited Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Economist Publications & Color Service Limited\", incorporated by letters patent dated 8th day of July, 1968, changing its name to that of \"Ken Hatton Associates Limited\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopcraties.44178-0 2832-68 Hawco Construction Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 12th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Hawco Construction Ltd.\", extending its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 13470-59 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.4 1045 Heartlands Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 28e jour de juillet 1971, à la compagnie « Heartlands Inc.», diminuant son capital de $10,000 à $9,000 par l'annulation de 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le sous-miiiistre des Institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 10301-59 Heartlands Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of July, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Heartlands Inc.\", reducing its capital from $10,000 to $9,000 by the cancellation of 100 preferred shares of the par value of $10 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 10301-59 International Railway Publishing Company (Limited) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 6e jour d'octobre 1971, à la compagnie « International Railway Publishing Company (Limited) », 1° diminuant son capital par l'annulation de 22,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune; 2° augmentant son capital par la création de 22,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune; Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 1089-27 Jardins Caprice inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour de janvier 1971, à la compagnie « Jardins Caprice inc.», 1° diminuant son capital de $40,000 à $5,000 par l'annulation de 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune; 2° augmentant son capital de $5,000 à $40,000 par la création de 30,000 actions privilégiées catégorie « A » d'une valeur au pair de $1 chacune et 5,000 actions privilégiées catégorie « B » d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-ministre des mstilutions financières, compagnies et coopéralives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 1820-69 Josel Realty Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 28e jour de juillet 1971, à la compagnie « Josel Realty Corp.», diminuant son capital de $10,000 à $9,000 par l'annulation de 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Lb-Puiuppe Bouchard.44178 10824-59 International Railway Publishing Company (Limited) Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 6th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"International Railway Publishing Company (Limited)\", 1.reducing its capital by the cancellation of 22,000 preferred shares of the par value of $1 each; 2.increasing its capital by the creation of 22,000 preferred shares of the par value of $1 each.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 1089-27 Jardins Caprice inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Jardins Caprice inc.\", 1.reducing its capital from $40,000 to $5,000 by the cancellation of 3,500 preferred shares of the par value of $10 each; 2.increasing its capital irom $5,000 to $40,000 by the creation of 30,000 class \"A\" preferred shares of the par value of $1 each and 5,000 class \"B\" preferred shares of the par value of $1 each.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 1820-69 Josel Realty Corp.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of July, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Josel Realty Corp.\", reducing its capital from $10,000 to $9,000 by the cancellation of 1,000 preferred shares of the par value of $1 each.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 10824-59 1046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i' année, n° l Kccnan-Ecclcs Printing Co.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 21c jour d'octobre 1971, à la compagnie « Keenan-Eccles Printing Co.Ltd.\u2022, 1\" diminuant son capital de $64,000 à $20,650 par l'annulation de 43,350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune; 2° augmentant son capital de $20,650 à $100,000 par la création de 79,350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives, Ls-Philippe Bouchard.44178 4403-63 Léonard Kurland Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 8e jour d'octobre 1971, à la compagnie «Léonard Kurland Inc.», 1° diminuant son capital de $10,000 à $7,000 par l'annulation de 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune; 2° augmentant son capital de $7,000 à 30,000 par la création de 23,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-ministre des iiistilutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 5467-63 W.J.Lafave & Sons Ltd.W.J Lafave & Fils ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour de novembre 1971, à la compagnie « W.J.Lafave & Sons Ltd.\u2014W.J.Lafave & Fils ltée-, convertissant 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune en 60 actions catégorie « A ¦ d'une valeur au pair de $100 chacune et 40 actions catégorie « B \u2022 d'une valeur au pair de $100 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 49160-53 Leader Industries Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 4c jour de novembre 1971, a la compagnie « Leader Industries Ltd.», étendant ses pouvoirs.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralives, Ls-Phiuppe Bouchard.44178 2062-64 Kccnan-Ecclcs Printing Co.Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Kecnan-Eccles Printing Co.Ltd.\", 1.reducing its capital from $64,000 to $20,650 by the cancellation of 43,350 preferred shares of the par value of $1 each: 2.increasing its capital from $20,650 to $100,000 by the creation of 79,350 preferred shares of the par value of $1 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 4403-63 Léonard Kurland Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 8th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Léonard Kurland Inc.\", 1.reducing its capital from $10,000 to $7.000 by the cancellation of 3,000 preferred shares of the par value of $1 each; 2.increasing its capital from $7,000 to $30.000 by the creation of 23,000 preferred shares of the par value of $1 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 5467-63 W.J.Lafave & Sons Ltd.W.J Lafave & Fils ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"W.J.Lafave S; Sons Ltd.\u2014 W.J.Lafave & Fils ltée\".converting 100 common shares of the par value of $100 each into 60 class \"A\" shares of the par value of $100 each and 40 class \"B\" shares of the par value of $100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 49160-53 Leader Industries Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 4th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooiwra-tives to \"Leader Industries Ltd.\", extending its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister nf Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 2062-64 ¦a QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1047 Madeleine Investments Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 28e jour de juillet 1971, à la compagnie « Madeleine Investments Inc.», diminuant son capital de 810,000 à 89,000 par l'annulation de 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 10299-59 Manyan Trading Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 4e jour d'octobre 1971, à la compagnie « Manyan Trading Corp.», modifiant les dispositions de ses lettres patentes.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 15578-59 Maple Ridge Investment Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 28e jour de juillet 1971, à la compagnie » Maple Ridge Investment Ltd.», diminuant son capital de $10,000 à $9,000 par l'annulation de 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralives, Ls-PniLippE Bouchard.44178 10959-59 Melran Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 25e jour d'octobre 1971, à la compagnie « Melran Corporation », étendant ses pouvoirs.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 2894-64 Montreal North Properties Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé deB lettres patentes supplémentaires en date du 22e jour d'octobre Madeleine Investments Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of July, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Madeleine Investments Inc.\", reducing its capital from $10,000 to $9,000 by the cancellation of 100 preferred shares of the par value of $10 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 10299-59 Manyan Trading Corp.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 4th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Manyan Trading Corp.\", modifying the provisions of its letters patent.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 15578-59 Maple Ridge Investment Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of July, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Maple Ridge Investment Ltd.\", reducing its capital from $10,000 to $9,000 by the cancellation of 1,000 preferred shares of the par value of $1 each.Ls-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 10959-59 Mclran Corporation Notice is hereby given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Melran Corporation\", extending its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 2894-64 Montreal North Properties Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 22nd day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and 1048 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 1971,àlacompagnie « MontrealNorthPropertiesLtd.», modifiant ses pouvoirs.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 5425-63 Murray & Company Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en dale du 20e jour d'octobre 1971, à la compagnie « Murray & Company Inc.», augmentant son capital de 820.000 à $170,000 par la création de 30.000 actions privilégiées de $5 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, cuiiipaynies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 1839-29 Oak Investment Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 28e jour de juillet 1971, à la compagnie « Oak Investment Corp.», diminuant son capital de $10,000 à $9,000 par l'annulation de 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 10951-59 Pampero Food Products Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour d'octobre 1971, à la compagnie « Pampero Ine.», constituée par lettres patentes en date du 23e jour de septembre 1969, changeant son nom en celui de « Pampero Food Products Inc.».Le sous-ministre des inslilulions financières, compagnies et coopéralives, Ls-Philippe Bouchard.44178 4569-69 Franz Patella Incorporated Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 8e jour de novembre 1971, à la compagnie « Franz Patella Incorporated\", subdivisant chaque action ordinaire d'une valeur au pair de $10 chacune en une action catégorie « A » d'une valeur au pair de $5 chacune et une action catégorie « B » d'une valeur au pair de $5 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.4417S 12360-62 Cooperatives to \"Montreal North Properties Ltd.\", modifying its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 5425-63 Murray & Company Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Murray & Company Inc.\", increasing its capital from $20,000 to $170,000 by the creation of 30,000 preferred shares of $5 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 1839-29 Oak Investment Corp.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of July, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Oak Investment Corp.\", reducing its capital from 810,000 to 89,000 by the cancellation of 1.000 preferred shares of the par value of 81 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44l78-o 10951-59 Pampero Food Products Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Pampero Inc.\", incorporated by letters patent dated 23rd day of September, 1969, changing its name to that of \"Pampero Food Products Inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 4569-69 Franz Patella Incorporated Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 8th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Franz Patella Incorporated\", subdividing each common share of the par value of $10 each into one class \"A\" share of the par value of $5 each and one class \"B\" share of the par value of $5 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister cr Market Ltd.», augmentant son capital par la création de 3,400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralives, Ls-Philippe Bouchard.44178 12280-61 Smiley's Super Market Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 9e jour de novembre 1971, à la compagnie « Smiley's Super Market Ltd.».diminuant son capital de 874,000 à 840.000 par l'annulation de 3.400 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies el cooperatives, Ls-Philippe Bouchard.44178 12280-61 Top Holdings Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 28e jour de juillet 1971, à la compagnie « Top Holdings Inc.-, diminuant son capital de 810,000 à 89.000 par l'annulation de 1.000 actions privilégiées de 81 chacune.Le sous-ministre des institutions financières.Companies et Cooperatives, Ls-Philippe Bouchard.44178 10067-59 United Dental Supply Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettre.-, patentes supplémentaires en date du 17e jour de février 1971, à la compagnie « Paterson & Patcrson, Incorporated », constituée par lettres patentes en date du 12c jour d'avril 1934, 1° changeant son nom en celui de « United Dental Supply Corporation » ; 2° modifiant ses pouvoirs; 3° augmentant son capital de $200,000 à Cooperatives to \"Saratoga Slacks Mfg.Inc.\", extending its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institution*, Companies and Cooperatives.44178-o 14768-58 Smiley's Super Market Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 13th day of October, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Smiley's Super Market Ltd.\", increasing its capital by the creation of 3,400 preferred shares of the par value of 810 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 12280-61 Smiley's Super Market Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Smiley's Super Market Ltd.\", reducing its capital from 874.000 to 840.000 by the cancellation of 3.400 preferred shares of the par value of 810 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 12280-61 Top Holdings Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act.supplementary letters patent, bearing date tie 28th day of July.1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Top Holdings Inc.\", reducing its capital from $10,000 to 89.000 by the cancellation of 1,000 preferred shares of the par value of 81 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-o 10067-59 United Dental Supply Corporation Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 17th day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Paterson & Partcrsoii.Incorporated\" incorporated by letters patent dated 12th day of April' 1934.1.changing its name to that of \"United Dental' Supply Corporation\"; 2.amending its powers' 3 in.creasing its capital from $200,000 to 8250.CC0 by the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.4 1051 $250,000 par la creation de 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $50 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 680-34 Venice Realties Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 28e jour de juillet 1971, à la compagnie « Venice Realties Ltd.», diminuant son capital de $10,000 à $9,000 par l'annulation de 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 13047-58 Verchères Realties Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 28e jour de juillet 1971, à la compagnie « Verchères Realties Ltd.», diminuant son capital de $10,000 à $9,000 par l'annula-ion de 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 13537-58 Wise Investments Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 2e jour de novembre 1971, à la compagnie « Wise Investments Ltd.», modifiant les dispositions de ses lettres patentes.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44178 10222-60 creation of 1,000 common shares of the par value of $50 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 680-34 Venice Realties Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of July, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Venice Realties Ltd.», reducing its capital from $10,000 to $9,000 by the cancellation of 100 preferred shares of the par value of $10 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 13047-58 Verchères Realties Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of July, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Verchères Realties Ltd.\", reducing its capital from $10,000 to $9,000 by the cancellation Of 1,000 preferred shares of the par value of $1 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44178-0 13537-58 Wise Investments Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 2nd day of November, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Wise Investments Ltd.\", modifying the provisions of its letters patent.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies aiui Cooperatives.44178-0 10222-60 Compagnies dissoutes Companies Dissolved Beau-Der Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Beau-Der Inc.», constituée en corporation le 7 janvier 1966, à compter du 14 janvier 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-o 66-66 Beau-Der Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of January 14, 1972, of the charter of- \"Beau-Der Inc.\", incorporated on January 7, 1966.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 06-66 1052 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i' année, n° A Bijouterie Jean B.Roy ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Bijouterie Jean B.Roy ltée », constituée en corporation le 18 septembre 1969, à compter du 14 janvier 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-u 4330-69 Jos.Blouin Alimentation inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Jos.Blouin Alimentation inc.-, constituée en corporation le 25 octobre 1968, à compter du 14 janvier 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-0 5009-68 Bolduc & Frères liée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Bol-duc & Frères ltée », constituée en corporation le 4 novembre 1963, à compter du 14 janvier 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-0 4680-63 Brimak Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Brimak Inc.», constituée en corporation le 31 octobre 1966, à compter du 14 janvier 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-0 4166-66 Canada Auto Leasing Co.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Canada Auto Leasing Co.Ltd.-, constituée en corporation le 1er mai 1963, à compter du 31 janvier 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-o 1400-63 Canadian Steel Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Canadian Steel Limited», constituée en corporation le 9 avril 1959, à compter du 14 janvier 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-o 11767-59 Bijouterie Jean B.Roy ltée Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of January 14, 1972, of the charter of \"Bijouterie Jean B.Rov ltée\", incorporated on September 18, 1969.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 4330-69 Jos.Blouin Alimentation inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of January 14, 1972, of the charter of \"Jos.Blouin Alimentation inc.\", incorporated on October 25, 1968.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44173 5009-68 Bolduc & Frères ltée Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of January 14, 1972, of the charter of \"Bolduc & Frères ltée\", incorporated on November 4, 1963.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 4680-63 Brimak Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératives has been pleased to accept the surrender, as of January 14, 1972, of the charter of \"Brimak Inc.\", incorporated on October 31, 1966.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 4166-66 Canada Auto Leasing Co.Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of January 31, 1972, of the charter of \"Canada Auto Leasing Co.Ltd.\", incorporated on May I, 1963.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 1400-63 Canadian Steel Limited Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies ' and Cooperatives has been pleased to accept the surrender as of January 14, 1972, of the charter of \"Canadian Steel Limited\", incorporated on April 9, 1959.Pierre Desjardins.Director of the Companies Service 44178 11767-59 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.à 1053 Le Club de Tennis de Joliette inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Le Club de Tennis de Joliette inc.», constituée en corporation le 8 juillet 1969, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-o .3211-69 Da Pasquali Restaurant, Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Da Pasquali Restaurant, Inc.», constituée en corporation le 17 février 1964, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-o 735-64 Les Entreprises B.C.M.liée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Les Entreprises B.C.M.ltée », constituée en corporation le 26 avril 1965, à compter du 14 janvier 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-0 1739-65 Hillsdale Investment Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Hillsdale Investment Corp.», constituée en corporation le 24 juillet 1956, à compter du 31 janvier 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-0 12197-56 L.S.G.Realties Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies, et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « L.S.G.Realties Corp.», constituée en corporation le 5 décembre 1960, à compter du 14 janvier 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-0 15352-60 Périka Construction Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de * Périka Construction Inc.», constituée en corporation le 3 août 1970, à compter du 14 janvier 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-o 3359-70 Le Club de Tennis de Joliette inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Le Club de Tennis de Joliette inc.\", incorporated on July 8, 1969.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 3211-69 Da Pasquali Restaurant, Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Da Pasquali Restaurant, Inc.\", incorporated on February 17, 1964.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 735-64 Les Entreprises B.C.M.ltée Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of January 14, 1972, of the charter of \"Les Entreprises B.C.M.ltée\", incorporated on April 26, 1965.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 1739-65 Hillsdale Investment Corp.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of January 31, 1972, of the charter of \"Hillsdale Investment Corp.\", incorporated on July 24, 1956.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 12197-56 L.S.G.Realties Corp.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions,.Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of January 14, 1972, of the charter of \"L.S.G.Realties Corp.\", incorporated on December 5, 1960.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 15352-60 Périka Construction Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of January 14, 1972, of the charter of \"Périka Construction Inc.\", incorporated on August 3, 1970.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 3359-70 1054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° l Prodor Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Prodor Inc.», constituée en corporation le 3 février 1967, à compter du 14 janvier 1972.Le directeur du service des vnpagnies, Pierre Desjardins.44178-o 209-67 P.J.Stein Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « P.J.Stein Inc.», constituée en corporation le 20 avril 1959, à compter du 14 janvier 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-0 12329-59 Techlem Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Techlem Inc.», constituée en corporation le 18 septembre 1963, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-o 4005-63 Théâtre Frontenac limitée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Théâtre Frontenac limitée », constituée en corporation le 28 avril 1937.à compter du 14 janvier 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44178-o 1199-37 Prodor Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of January 14, 1972, of the charter of \"Prodor Inc.\" incorporated on February 3, 1967.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 209-67 P.J.Stein Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of January 14, 1972, of the charter of \"P.J.Stein Inc.\", incorporated on April 20, 1959.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 12329-59 Techlem Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Techlem Inc.\", incorporated on September 18, 1963.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 4005-63 Théâtre Frontenac limitée Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of January 14, 1972, of the charter of \"Théâtre Frontenac limitée\", incorporated on April 28, 1937.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 1199-37 Ministère des Terres et Forêts Cadastre Department of Lands and Forests Cadastre Village d'Arthabaskaville Cadastre officiel du village d'Arthabaskaville, municipalité de la ville d'Arthabaska, division d'enregistrement de Arthabaska.Avis est par la présente donné que les lots 302-142, 302-143, 302-182 à 302-187 sont annulés en vertu de l'article 2I74A du Code civil.Québec, le 22 décembre 1971.Le sous-ministre adjoint, 44248-0 Jean-Marie Bourbeau.Paroisse de Charlcsbourg Cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg, municipalité de la ville de Charlesbourg, division d'enregistrement de Québec.Village of Arthabaskaville Officiai cadastre of village of Arthabaskaville, municipality of the town of Arthabaska, registration division of Arthabaska.Notice is hereby given that lots 302-142, 302-143 302-182 to 302 187 are cancelled in virtue of Article\" 2174A of the Civil Code.Québec, December 22, 1971.Jean-Marie Bourbeau 44248-° Assistant Deputy Minister.Parish of Charlesbourg Official cadastre of the parish of Charlesbourg, municipality of the town of Charlesbourg, registration division of Québec.À QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.4 1055 Avis est par la présente donné que les lots 682-1-138-1 et 682-1-138-2 (avec effet rétroactif au 2 octobre 1961) sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 22 décembre 1971.Le sous-minisire adjoint, 44248-0 Jean-Marie Bourbeau.Paroisse de Charlesbourg Cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg, municipalité de la ville d'Orsainville, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 639-15 à 639-17 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 14 décembre 1971.Le sous-ministre-adjoint, 44248-0 Jean-Marie Bourbeau.Cité de Québec (Quartier Montcalm) Cadastre officiel de la cité de Québec, (Quartier Montcalm), municipalité de la ville de Québec, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que le lot 4525 est ajouté et que les lots 4381-70-A.4381-70-B, 4381-71-A, 4381-71-B, 4381-85-A, 4381-85-B, 4381-66 à 4381-71.4381-82 à 4381-86 et qu'une partie du lot 4381-57-E et que la partie correspondante du lot 4381 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 20 décembre 1971.Le sous-ministre-adjoint, 44248-o Jean-Marie Bourbeau.Canton de Laflèche Cadastre officiel du canton de Laflèche, municipalité de la ville de Hauterive, division d'enregistrement de Saguenay.Avis est par la présente donné que le lot F-192 du Rang I est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 21 décembre 1971.Le sous-ministre-adjobit, 44248-o Jean-Marie Bourbeau.Paroisse de Laprairie de la Magdelcine Cadastre officiel de la paroisse de Laprairie de la Magde-leine, municipalité de la Ville de Brossard, division d'enregistrement de Laprairie.Avis est par la présente donné que les lots 136-173-1 et 136-173-2 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 29 décembre 1971.Le sous-ministre-adjoint, 44248-0 Jean-Marie Bourbeau.Canton de McKenzie Cadastre officiel de Canton de McKenzie, municipalité de la Ville de Chibougamau, division d'enregistrement de Lac St-Jean-Ouest.Notice is hereby given that lots 682-1-138-1 and 682-1-138-2 (with effect retroactive in October 2, 1961) are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 22, 1971.Jean-Marie Bourbeau, 44248-o Assistant Deputy Minister.Parish of Charlesbourg Official cadastre of the parish of Charlesbourg, municipality of the town of Orsainville, registration division of Québec.Notice is hereby given that lots 639-15 to 639-17 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec.December 14, 1971.Jean-Marie Bourbeau, 44248-o Assistant Deputy Minister.City of Québec (Montcalm Ward) Official Cadastre of the city of Québec (Montcalm Ward), municipality of the town of Québec, registration division of Québec.Notice is hereby given that lots 4525 is added and that lots 43S1-70-A, 4381-70-B, 4381-71-A, 4381-71-B, 4381-85-A, 4381-85-B, 4381-66 to 4381-71, 4381-82 to 4381-86 and a part of lot 4381-57-E and the corresponding part of lot 4381 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 20, 1971.Jean-Marie Bourbeau, 44248-o Assistant Deputy Minister.Township of Laflèche Official cadastre of township of Laflèche, municipality of the town of Hauterive, registration division of Saguenay.Notice is hereby given that lot F-192 of Range I is cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 21, 1971.Jean-Marie Bourbeau, 44248-0 Assistait! Deputy M blister.Parish of Laprairie de la Magdeleine Official cadastre of the parish of Laprairie de la Magdeleine, municipality of the Town of Brossard, registration division of Laprairie.Notice is hereby given that lots 136-173-1 and 136-173-2 are cancelled in virtue of article 2174A of the Civil Code.Québec, December 29, 1971.Jean-Marie Bourbeau, 44248-0 Assistant Deputy Minister.Township of McKenzie Official cadastre of Township of McKenzie, municipality of the Town of Chibougamau, registration division of Lac St-Jean West. 1056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Avis est par la présente donné que les lots 1398 à 1401 du bloc « D » sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 15 décembre 1971.Le sous-ministre-adjoint, 44248-0 Jean-Marie Bourbeau.Municipalité de la paroisse de Montréal Cadastre officiel de la municipalité de la paroisse de Montréal, municipalité de la Cité de la Côte St-Luc, division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 4843 et 4844 sont ajoutés et que deux (2) partie du lot 83 sont annulées en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 7 janvier 1972.Le sous-ministre adjoint, 44248-o Jean-Marie Bourbeau.Paroisse de Notre-Dame de l'Assomption de Repentigny Cadastre officiel de la Paroisse de Notre-Dame de l'Assomption de Repentigny, municipalité de la Ville de Repentigny, division d'enregistrement de L'Assomption.Avis est par la présente donné que les lots 170-11, 170-12 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 20 décembre 1971.Le sous-ministre adjoint, 44248-o Jean-Marie Bourbeau.Paroisse de Ste-Anne de la Pocatière Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Anne de la Poea-tière, municipalité de la ville delà Pocatièrc, division d'enregistrement de Kamouraska.Avis est par la présente donné que les lots 311-4-4 à 311-4-11, 308-3-5 à 308-3-17 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 21 décembre 1971.Le sous-ministre adjoint, 44248-0 Jean-Marc Bourbeau.Paroisse de St-Antoine de Longueuil Cadastre officiel de la paroisse de St-Antoine de Longueuil, municipalité de la ville de St-Hubert, division d'enregistrement de Cliambly.Avis est par la présente donné que la partie restante du lot 224-90 est annulée en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 16 décembre 1971.Le sous-ministre adjoint, 44248-0 Jean-Marie Bourbeau.Paroisse de St-Eustache Cadastre officiel de la paroisse de St-Eustache, municipalité de la ville de St-Eustache, division d'enregistrement de Deux-Montagnes.Notice is hereby given that lots 1398 to 1401 of Block \"D\" are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 15, 1971.Jean-Marie Bourbeau, \u20221424s-0 Assistant Deputy Minister.Municipality of Ihc Parish of Montreal Official cadastre of the municipality of the parish of Montreal, municipality of the City of Côte St-Luc, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 4843 and 4844 are added and that two (2) parts of lot 83 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, January 7, 1972.Jean-Marie Bourbeau, 44248-o Assistant Deputy Minister.Parish of Notre-Dame de l'Assomption of Repentigny Official cadastre of the parish of Notre-Dame de l'Assomption of Repentigny, municipality of the Town of Repentigny, registration division of L'Assomption.Notice is hereby given that lots 170-11, 170-12 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 22, 1971.Jean-Marie Bourbeau, 44248-o Assistant Deputy Minister.Parish of Ste-Anne de la Pocatièrc Official cadastre of the parish of Ste-Anne de la Poca-tière, municipality of the town of La Pocatièrc, registration division of Kamouraska.Notice is hereby given that lots 311-4-4 to 311-4-11.308-3-5 to 308-3-17 arc cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 21, 1971.Jean-Marc Bourbeau, 44248-0 Assistatit Deputy Minister.Parish of St-Antoine de Longueuil Official Cadastre of the parish of St-Antoine de longueuil, municipality of the town of St-Hubcrt, registration division of Chambly.Notice is hereby given that the remaining part of lot 224-90 is cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 16, 1971.Jean-Marc Bourbeau, 44248-o Assistaiit Deputy Minister.Parish of St-Eustache Official cadastre of the parish of St-Eustache, municipality of the town of St-Eustache, registration division of Deux-Montagnes.1 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.k 1057 Avis est par la présente donné que les lots 284-29 à 284-36, 284-49, 284-195 à 284-198, 284-200 à 284-203 et qu'une partie des lots 284-189 à 284-194, 284-199 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 2 décembre 1971.Le sous-ministre adjoint, 44248-0 Jean-Marc Bourbeau.Paroisse de St-Féréol Cadastre officiel de la paroisse de St-Féréol, municipalité de la paroisse de St-Féréol les Neiges, division d'enregistrement de Montmorency.Avis est par la présente donné que les lots 649-158, 649-154, 649-159 et 649-153 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 23 décembre 1971.Le sous-ministre adjoint, 44248-0 Jean-Marc Bourbeau.Paroisse de St-Joseph du Lac Cadastre officiel de la paroisse de St-Joseph du Lac, municipalité du village de Pointe-Calumet, division d'enregistrement de Deux-Montagnes.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 36-11 est annulée en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 23 novembre 1971.Le sous-ministre adjoint, 44248-o Jean-Marc Bourbeau.Paroisse de St-Martin Cadastre officiel de la paroisse de St-Martin, municipalité de la ville de Laval, division d'enregistrement de Laval.Avis est par la présente donné que les lots 654-14-2 et 654-15-2 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 28 décembre 1971.Le sous-ministre adjoint, 44248-o Jean-Marie Bourbeau.Paroisse de St-Philippe Cadastre officiel de la paroisse de St-Philippe, municipalité de la paroisse de St-Philippe, division d'enre-gis trement de Laprairie.Avis est par la présente donné que les lots 266-1 à 266-8 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 22 décembre 1971.Le sous-ministre adjoint, 44248-0 Jean-Marie Bourbeau.Paroisse de St-Romuald d'Etchcmin Cadastre officiel de la paroisse de St-Romuald d'Etche-min, municipalité de la cité de St-Romuald d'Etche-min, division d'enregistrement de Lévis.Notice is hereby given that lots 284-29 to 284-36, 284-49, 284-195 to 284-198, 284-200 to 284-203 and that a part ot lots 284-189 to 284-194, 284-199 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 2, 1971.Jean-Marc Bourbeau, 44248-o Assistant Deputy Minister.Parish of St-Féréol Official cadastre of the parish of St-Féréol, municipality of the parish of St-Féréol les Neiges, registration division of Montmorency.Notice is hereby given that lots 649-158, 649-154, 649-159 and 649-153 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 23, 1971.Jean-Marc Bourbeau, 44248-o Assistant Deputy Minister.Parish of St-Joseph du Lac Official cadastre of the parish of St-Joseph du Lac, municipality of the village of Pointe-Calumet, registration division of Deux-Montagnes.Notice is hereby given that a part of lot 36-11 is cancelled in virtue of Article 2174À of the Civil Code.Québec, November 23, 1971.Jean-Marc Bourbeau, 44248-o Assistant Deputy Minister.Parish of St-Martin Official cadastre of the parish of St-Martin, municipality of the town of Laval, registration division of Laval.Notice is hereby given that lots 654-14-2 and 654-15-2 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 28, 1971.Jean-Marie Bourbeau, 44248-0 Assistant Deputy Minister.Parish of St-Philippc Official cadastre of the parish of St-Philippe, municipality of the parish of St-Philippe, registration division of Laprairie.Notice is hereby given that lots 266-1 to 266-8 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 22, 1971.Jean-Mahie Bourbeau, 44248-0 Assistaid Deputy Minister.Parish of St-Roniuald d'Etchemin Official cadastre of the parish of St-Romuald d'Etchemin, municipality of the City of St-Romuald d'Etchemin, registration division of Levis. 1058 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n\" 4 Avis est par la présente donné que les lots 465, 466, 468.469 et qu'une partie du lot 469-A n.s.sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 14 décembre 1971.Le sous-ministre adjoint, 44248-0 Jean-Marie Bourbeau.Canton Signai Cadastre officiel de canton Signai, municipalité de la cité d'Alma, division d'enregistrement de Lac St-Jean est.Avis est par la présente donné que les lots 17A-314 à 17A-319, 17A-321, 17A-363, 17A-364, 17A-400 à 17A-403 du Rang IX sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 17 décembre 1971.Le sous-ministre adjoint, 44248-0 Jean-Marie Bourbeau.Canton de Winslow Cadastre officiel du canton de Winslow, municipalité de St-Romain*, division d'enregistrement de Frontenac.Avis est par la présente donné que les lots 2a et 3a du Rang VII nord-est sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 29 novembre 1971.Le sous-ministre adjoint, 44248-0 Jean-Marie Bourbeau.Avis Concernant la mise à jour partielle du cadastre dans les paroisses de Saint-Augustin.Saint-Benoit, Saint-Canut, Saint-Hermas, Saint-Janvier, Saint-Jérôme, Sainte-Scliolastiquc et Sainte-Thérèse-de-Blainville faisant partie des divisions d'enregistrement de Deux-Montagnes et Terrebonne.Les propriétaires concernés par les travaux de mise à jour du cadastre dans les paroisses de Saint-Augustin, Saint-Benoit, Saint-Canut, Saint-Hermas, Saint-Janvier, Saint-Jérôme, Sainte-Scholastique et Sainte-Tliérèse-de-Blainville, qui ne se sont pas présentés à l'examen, en séance publique, des documents relatifs aux subdivisions de certains lots faisant partie des entités cadastrales mentionnées plus liaut et qui, par la suite, n'ont pas signé la requête prévue au paragraphe « a » de la section 3, chapitre 104 des Lois 1930-1931, sont invités, s'ils le désirent, à m exposer, par écrit ou verbalement, les motifs qu'ils allèguent à rencontre de cette requête, et ce, pendant la période se terminant le quinze (15) mars mil neuf cent soixante-douze (1972).Par la suite, si je considère que je peux donner suite à la requête avec ou sans modification après avoir, s'il y a lieu, examiné les motifs exposés de part et d'autre ou entendu les parties intéressées qui auront comparu devant moi, je pourrai permettre qu'un plan et qu'un livre de renvoi de la subdivision de ce terrain ou partie de terrain soient faits pourvu que les formalités prévues Notice is hereby given that lots 465, 466.468, 469 and a part of lot 469-A n.s.arc cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 14, 1971.Jean-Marie Bourbeau, 44248-o Assistant Deputy Minister.Township of Signai Official cadastre of township of Signai, municipality of the city of Alma, registration division of Lake St-Jean east.Notice is hereby given that lots 17A-314 to 17A-319, 17A-321, 17A-363, 17A-364, 17A-400 to 17A-403 of Range IX are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 17, 1971.Jean-Marie Bourbeau, 44248-o Assistant Deputy Minister.Township of Winslow Official cadastre of township of Winslow, municipality of St-Romain*, registration division of Frontenac.Notice is hereby given that lots 2a and 3a of Range VII northeast are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, November 29.1971.Jean-Marie Bourbeau, 44248-0 Assistant Deputy Minister- Notice Concerning the partial cadastral revision in the parishes of St.Augustin, St.Benoit, St.Canut, St.Hernias, St.Janvier, St.Jérôme, St.Scholastique and St.Thérèse-de-Blainville forming part of the Two Mountains and Terrebonne Registration Divisions.Proprietors affected by the cadastral revision in the parishes of St.Augustin, St.Benoit, St.Canut, St.Hernias, St.Janvier, St.Jérôme, St.Scholastique and St.Thérèse-de-Blainville, who did not attend the publicly held examination of documents with respect to the subdivisions of certain lots forming part of the aforementioned cadastral units, and who did not thereafter sign the petition provided for in paragraph \"a\" of section 3, chapter 104 of the Statutes of 1930-1931, may make known to me, either verbally or in writing, their reasons for opposing this petition\".Such notification must be conveyed to me not later than March fifteenth (15), one shousand nine hundred and seventv-two (1972).' Thereafter, if, upon examination of the arguments for and against the granting of this petition, and having given audience to interested parties, I consider that the petition should be granted, in amended form or otherwise, I may permit a plan and book of reference of the subdivision of this territory, or part thereof to be made, provided that the formalities prescribed in QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.L 1059 aux paragraphes la, 16, le et Id de la section 4, chapitre 104 des Lois 1930-1931 soient observées.Québec, le 14 janvier 1972.Le ministre des Terres et Forets, 44250-4-4-o Kevin Drummond.paragraphs la, 16, le and Id of section 4, chapter 104 of the 1930-1931 Statutes are complied with.Québec, January 14, 1972.Kevin Drummond, 44250-4-4 Minister of Lands and Forests.Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Change of name \u2014 Act Granted Joseph René Briand Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 19, du 7 janvier 1972, d'effectuer le changement de nom de Joseph Rémi Briand en celui de Joseph René Briand.Québec, le 19 janvier 1972.Robert Normand, 44256-0 Sous-miiiistre de la Justice.Joseph René Briand It has pleased the Lieutenant-Governor in Council, by order number 19, dated January 7, 1972, to change the name of Joseph Rémi Briand to that of Joseph Rene Briand.Québec, January 19, 1972.Robert Normand, 44256 Deputy Minister of Justice.Lynden Maynard Bruce Campbell Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 88.du 12 janvier 1972, d'effectuer le changement de nom de Linden Bruce Cameron en celui de Lynden Maynard Bruce Campbell.Québec, le 19 janvier 1972.Robert Normand, 44256-0 Sous-ministre de la Justice.Lynden Maynard Bruce Campbell It has pleased the Lieutenant-Governor in Council, by order number S8.dated January 12, 1972, to change the name of Linden Bruce Cameron to that of Lynden Maynard Bruce Campbell.Québec, January 19, 1972.Robert Normand, 44256 Deputy Miuister of Justice.Suzan Carmeli Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 20, du 7 janvier 1972, d'effectuer le changement de nom de Shoshanna Carmeli en celui de Suzan Carmeli.Québec, le 19 janvier 1972.Robert Normand, 44256-0 Sous-ministre de la Justice.Suzan Carmeli It has pleased the Lieutenant-Governor in Council, by order number 20, dated January, 7, 1972, to change the name of Shoshanna Carmeli to that of Suzan Carmeli.Québec, January 19, 1972.Robert Normand, 44256 Deputy Minister of Justice.Marie Clara Noëlla Pauline Dostie Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 21, du 7 janvier 1972, d'effectuer le changement de nom de Marie-Clara-Noclla Dostie en celui de Marie Clara Noëlla Pauline Dostie.Québec, le 19 janvier 1972.Robert Normand, 44256-0 Sous-ministre de la Justice.Julius Henry Grey Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 89, du 12 janvier 1972, d'effectuer le changement de nom de Juliusz-Henryk Gryj en celui de Julius Henry Grey.Québec, le 19 janvier 1972.Le sous-ministre de la Justice, 44256-0 Robert Normand.Marie Clara Noëlla Pauline Dostie It has pleased the Lieutenant-Governor in Council, by order number 21, dated January 7, 1972, to change the name of Marie-Clara-Noëlla Dostie to that of Marie Clara Noëlla Pauline Dostie.Québec, January 19, 1972.Robert Normand, 44256 Deputy Minister of Justice.Julius Henry Grey It has pleased the Lieutenant-Governor in Council, by order number 89, dated January 12, 1972, to change the name of Juliusz-Henryk Gryj to that of Julius Henry Grey.Québec, January 19, 1972.Robert Normand, 44256 Deputy Minister of Justice. 1060 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S9 janvier 197S, 104' année, n° 4 Jack Packer Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 90, du 12 janvier 1972, d'effectuer le changement de nom de Jack Pecker en celui de Jack Packer.Québec, le 19 janvier 1972.Robert Normand, 44256-o Sous-ministre de la Justice.Henri Charles Rothschild E a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 91, du 12 janvier 1972, d'effectuer le changement de nom de Henri Charles Rotszyld en celui de Henri Charles Rothschild.Québec, le 19 janvier 1972.Robert Normand, 44256-0 Sous-ministre delà Justice.Stanley Smiley Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 22, du 7 janvier 1972, d'effectuer le changement de nom de Stanley Smilovitch en celui de Stanley Smiley.Québec, le 19 janvier 1972.Robert Normand, 44256-0 Sous-ministre de la Justice.Jack Packer It has pleased the Lieutenant-Governor in Council, by order number 90, dated January 12, 1972, to change the name of Jack Pecker to that of Jack Packer.Québec, January 19, 1972.Robert Normand, Deputy Minister of Justice.44256 Henri Charles Rothschild It has pleased the Lieutenant-Governor in Council, by order number 91, dated January 12, 1972, to change the name of Henri Charles Rotszyld to that of Henri Charles Rothschild.Québec, January 19, 1972.Robert Normand, 44256 Deputy Minister of Justice.Stanley Smiley It has pleased the Lieutenant-Governor in Council, by order number 22, dated January 7, 1972, to change the name of Stanley Smilovitch to that of Stanley Smiley.Québec, January 19, 1972.Robert Normand, 44256 Deputy Minister of Justice.Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Change of name \u2014 Act Applications Felicia Steigman Hefler Carmelly Avis est donné que Felicia Steigman Hefter Carmelly, travailleuse sociale, domiciliée et résidant de la cité de Côte St-Luc, district de Montréal, province de Québec, et résidant au numéro civique 5755 Sir Walter Scott, appartement 211, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Felicia Carmelly.Montréal, 7 janvier 1972.Les procureurs de requérant, Tinkoff, Seal, Siiaposnick 44025-3-2-o & Moscowitz.William Gitlitz Avis est donné par les présentes que William Gitliz de la cité et district de Montréal, et résidant et domicilié au 2055 rue Crescent, app.16, a fait une requête pour changer son nom pour William Charles Gardner en vertu des dispositions de la Loi du changement de nom.Les procureurs du requérant, Gliserman, Ackman, Cutler 44107-3-2-q & Boidman.Felicia Steigman Hefter Carmelly Notice is given that Felicia Steigman Hefter Carmelly, Social Worker, of the city of Côte Saint-Luc, district of Montreal, in the Province of Québec and therein residing and domiciled at 5755 Sir Walter Scott, Apartment 211, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing her name to Felicia Carmelly.Montreal, January 7, 1972.Tinkoff, Seal, Siiaposnick & Moscowitz, 44025-3-2-o Attorneys for the applicant.WiUiam Gitlitz Notice is hereby given that William Gitlitz of the city and district of Montreal, and therein residing and domiciled at 2055 Crescent Street, Apt.16, is making an application for change of name into William Charles Gardner under the provisions of the change of Name Act.Gliserman, Ackman, Cutler Boidman, 44107-3-2-o Attorney for the applicant. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1061 Joseph Biron dit Raymond Prenez avis que monsieur Joseph Biron dit Raymond, menuisier, domicilié et résidant au 4525, boulevard St-Charlcs à Pierrefonds, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Joseph Raymond.Les autres personnes dont les noms devraient être changés par le décret sont: Dame Marie-Thérèse Gamelin, son épouse, également domiciliée avec le requérant à la même adresse et ses enfants ci-après nommés: Joseph Robert Claude Biron dit Raymond, Joseph Léo Gaétan Biron dit Raymond et Joseph Ovila Marcel Biron dit Raymond.Montréal, ce 17 janvier 1972.Le procureur du requérant, 44251-4-2-0 Jacques Monceau.Dan Virgil Plesoeanu Avis est donné que Dan Virgil Plesoeanu, économiste, domicilié au 201 Corot Rive, Ile des Soeurs, Verdun, district de Montréal, s'adressera au ministre de la Justice de la Province de Québec en vue d'obtenir un décret du lieutenant-gouverneur en conseil changeant son nom en celui de Dan Virgil Pleshoyano.44182-4-2-o Dan V.Plesoeanu.Julie Yampolsky (Pollack) Avis est donné que Dame Julie Yampolsky (Pollack) résidant à 5565 Avenue Clanranald, ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Julie YVainer, ledit nom devant servir à toutes fins légales.Montréal, Québec, le 18 janvier, 1972.Le procureur de la requérante, 44234-4-2-o Max Slapack, c.b.Joseph Biron dit Raymond Take notice that Mr.Joseph Biron dit Raymond, carpenter, residing and domiciled *at 4525, St-Charles Blvd.Pierrefonds, in the district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the change of his name to Joseph Raymond.Other persons whose names would be changed by the order are: his wife.Dame Marie-Thérèse Gamelin, also residing with the applicant at the same address, and his children, namely Joseph Robert Claude biron dit Raymond, Joseph Léo Gaétan Biron dit Raymond and Joseph Ovila Marcel Biron dit Raymond.Montreal, January 17, 1972.Jacques Monceau, 44251-4-2-0 Attorney for applicant.Dan Virgil Plesoeanu Notice is given that Dan Virgil Plesoeanu, economist, domiciled at 201 Corot Rive, Nuns' Island, Verdun, District of Montreal, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec for a decree of the Lieutenant-Governor in Council changing his name to that of Dan Virgil Pleshoyano.44182-4-2-o Dan V.Plesoeanu.Julie Yampolsky (Pollack) Notice is hereby given that Dame Julie Yampolsky (Pollack) residing at 5565 Clanranald Avenue in the City and District of Montreal will apply to the Lieutenant-Governor in Council in order to obtain the adoption of a decree changing her name to that of Julie Wainer, the said name to serve for all legal purposes.Montreal, Québec, January 18, 1972.Max Slapack, q.c., 44234-4-2-0 Attorney for Applicant.Charte \u2014 demandes d'abandon de Charter \u2014 Applications for Surrender of A.D.Amyot inc.Avis est par les présentes donné que la compagnie « A.D.Amyot inc.», demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie, 44187-0 Valiquette, Blouin & Kochenburger.Boulangerie F.Doyon & Fils ltée Avis est donné que la compagnie « Boulangerie F.Doyon & Fils ltée », de St-Martin, Beauce, demandera au ministre des institutiors financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Ville St-Georges, le septième jour de janvier mil neuf cent soixante-douze.Le procureur de la compagnie, 44189-0 Me Claude Guebtin, notaire.A.D.Amyot inc.Notice is hereby given that the company \"A.D.Amyot inc.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Valiquette, Blouin & Kochenburger, 44187-0 Attorneys for the Company.Boulangerie F.Doyon & Fils ltée Notice is given that \"Boulangerie F.Doyon & Fils ltée\", of St.Martin, Beauce, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Town of St.Georges, the seventh day of January, one thousand nine hundred and seventy-two.Me Claude Guertin, Notary, 44189 Attorney for the Company. 1062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10A- année, n° A Bonnaire Mortgage Corporation La compagnie « Bonnaire Mortgage Corporation », constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal, donne avis qu'elle s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, 13 janvier 1972.Le secrétaire, 44188 David Holt.Bonnaire Mortgage Corporation Notice is given that \"Bonnaire Mortgage Corporation\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter, under the provisions of the Companies Act.Montreal, January 13, 1972.David Holt, 441S8-0 Secretary.Centre d'achats ouvrier (Montréal) inc.Avis est donné que la compagnie « Centre d'achats ouvrier (Montréal) inc.», une corporation dûment incorporée en vertu de la Loi des compagnies et ayant sa place d'affaires dans la ville de Montréal, district de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Daté à Longueuil, ce 12e jour de janvier 1972.Les procureurs de la compagnie, 44190-o Brissette, St-Jacques & Dureault.Centre d'achats ouvrier (Montréal) inc.Notice is hereby given that \"Centre d'achats ouvrier (Montréal) inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Longueuil, this 12th day of January, 1972.Brissette, St-Jacques & Dureault.44190-o Attorneys for the Company.Allied International Products Inc.Avis est donné que la compagnie « Allied International Products Inc.», constituée en vertu de la Loi des compagnies, ayant son siège social à Québec, dans le district de Québec, province de Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Québec, le 4 janvier 1971.Les procureurs de la compagnie, L'Heureux, Philippon, Garneau, 44257-0 Touricny & St-Arnaud.Albany Investment Corporation Avis est donné que « Albany Investment Corporation » une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux disposition de la Loi des compagnies.Montréal, le 28 décembre 1971.Avocate de la requérante, 2, avenue McCulloch, Blanka Gyulai.Montréal 153.44258-0 Comptoir du jardin inc.Avis est donné que la compagnie « Comptoir du jardin inc.», demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 44260-o Me François Rainville, Notaire.Allied International Products Inc.Notice is given that \"Allied International Products Inc.\", incorporated under the Companies Act having its head office in Quebec City, in the District of Québec, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Québec, January 4.1972.L'Heubeux, Phili'ppon, Garneau, Tourignv & St-Arnaud, 44257-o Attorneys for the Company.Albany Investment Corporation Notice is given that \"Albany Investment Corporation\" a corporation incorporated under the Companies Act having its head office in Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal.December 28, 1971.Blanka Gyulai, Attorney for Petitioner.44258-0 2, McCulloch Avenue, Montreal 153.Comptoir du jardin inc.Notice is given that \"Comptoir du jardin inc.\", will apply to Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province for leave to surrender its charter.M* François Rainville, Notary, 44260-O Attorney for the company. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1063 \u2022 Barry Children's Wear Inc.La compagnie « Barry Children's Wear Inc.», ayant son siège social en la ville de Montréal, province de Québec, donne avis qu'elle demandera la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec.Montréal, 1S janvier 1972.Le secrétaire, 44259 Molly Bultz.R.Delvoyc Inc.Avis est donné que la compagnie \" R.Delvoye Inc.», demandea au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 20 janvier 1972.Les procureurs de la compagnie, 44261-0 YELIN & KlRSHENBLATT.Barry Children's Wear Inc.Notice is hereby given that \"Barry Children's Wear Inc.\", which has its head office in the city of Montreal, Province of Québec, will make application for leave to surrender its charter in accordance with the provisions of the Companies Act, Part I.Montreal, January 18, 1972.Molly Bultz, 44259-0 Secretary.R.Delvoye Inc.Notice is given that \"R.Delvoye Inc.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, this January 20, 1972.Yelin & Kihsiienblatt, 44261-o Attorneys for Petitioner.La Compagnie de Gestion J.Noël Tessier inc.Avis est donné par la présente que « La Compagnie de Gestion J.Noël Tessier inc.», de Baie-Comeau, en vertu de la Loi des compagnies, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Cette compagnie a sa principale place d'affaires dans la cité de Baie-Comeau.Donné à Baie-Comeau, ce 7e jour de janvier 1972.Les procureurs de la compagnie, Girouard, Beaumier, Huard, 44191-0 \u2022 GuÈVREMONT & RlCUARD.La Compagnie de Gestion J.Noël Tessier inc.Notice is hereby given that \"La Compagnie de Gestion J.Noël Tessier inc.\", of Baie-Comeau, according to the Companies Act will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to we permit to surrender its charter in the city of Baie-Comeau.Given at Baie-Comeau, this 7th day of January 1972.Girouard, Beaumier, Huard, g uèvr f.mont & rlchard, 44191-0 Attorneys for the Company.Rubin Investment Corp.La compagnie « Rubin Investment Corp.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal, donne avis qu'elle s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 14e jour de janvier 1972.(Sceau) Le secrétaire, 44192 Mme Roran Rubin.Rubin Investment Corp.Notice is hereby given that \"Rubin Investment Corp.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 14th day of January, 1972.(Seal) Mrs.Roran Rubin, 44192-0 Secretary.Textile Promotions Ltd.Avis est par les présentes donné que « Textile Promotions Ltd.», une corporation incorporée sous la Loi des compagnies, et ayant son bureau chef dans les cité et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte sous les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 30e jour de novembre, 1971.Le secrétaire, 44193-o Stephen Harrison.Textile Promotions Ltd.Notice is hereby given that \"Textile Promotions Ltd.\", a corporation constituted under the Companies Act, and having its head office in the city and district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter, pursuant to the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 30th day of November 1971.Stephen Harrison, 44193 Secretary. 1064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 janvier 1972, 104' année.n° 4 The Station Viauville Inc.Avis est donné que la compagnie « The Station Viauville Inc.» constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social au numéro 995 de la rue du Palais, en les cité et district de Saint-Hyacinthe, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Saint-Hyacinthe, ce 14e jour de janvier 1972.Les procureurs de la compagnie, 44231-0 Nichols & Robert, avocats.The Station Viauville Inc.Notice is given that \"The Station Viauville Inc.\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office, 995, du Palais in the city of St.Hyacinthe, district of St.Hyacinthe, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of said Companies Act.Dated at Saint-Hyacinthc, this 14th day of January, 1972.Nichols & Robert, Advocates, 44231-0 Attorneys for the Company.Les Entreprises Kurvclte.lice Avis est donné que la compagnie « Les Entreprises Korvctte ltée » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le secrétaire-trésorier, 44262-0 Serge Binette.Les Entreprises Korvelte ltée Notice is given that \"Les Entreprises Korvette ltée\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Serge Binette, 44262-0 Secretary-Treasurer.Gauvrcau Machinery & Supply Limited Gauvreau Machinery & Supply Limited Avis est par les présentes donné que la compagnie « Gauvreau Machinery & Supply Limited », demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Les avocats, 44263-0 Valiquette, Blouin & Kochenburger.Notice is hereby given that the company \"Gauvreau Machinery & Supply Limited\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Valiquette, Blouin & Kochenburger, 44263-0 Attorneys.Neptal Properties Limited Avis est par la présente donné que « Neptal Properties Limited », une compagnie constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et dont le bureau principal est situé dans Montréal, dans le district de Montréal, province de Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, ce 17e jour de janvier 1972.Le trésorier, 44264-0 H.E.Parsons.Neptal Properties Limited Notice is hereby given that \"Neptal Properties Limited\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city and district of Montreal, province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, this 17th day of January, 1972.H.E.Parsons, 44264-0 Treasurer.Placements F.B.L.inc.Avis est par les présentes donné que « Placements F.B.L.inc.», une compagnie constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de ladite loi.Daté à Montréal, ce lie jour de janvier 1972.Les administrateurs, Ginette Murray, Danielle Trudel, 44265-0 Thérèse Séguin.Placements F.B.L.inc.Notice is hereby given that \"Placements F.B.L.inc.\", a company duly incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the said act.Dated at Montreal, this 11th day of January, 1972.Ginette Murray, Danielle Trudel, .,\u201e.Thérèse Séguin, ^SS-o Directors. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1065 Adélard Sévigny inc.Avis est donné que « Adélard Sévigny inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Trois-Rivières, le 20 janvier 1972.Les procureurs de la compagnie, 44266-0 Bouchard & Langevin.Adélard Sévigny inc.Notice is given that \"Adélard Sévigny inc.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Trois-Rivières, January 20, 1972.Bouchard & Langevin, 44266-0 Attorneys for the company.Divers Compagnies Miscellaneous Companies I.es Placements Collectifs inc.Collective Investments Inc.La compagnie « Les Placements Collectifs inc.\u2014 Collective Investments Inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 14 à 5.Le secrétaire, Jacques V.Goyer.44267-0 12120-56 Le Service des Loisirs de Saint Jean-de-Matha de Montréal incorporé Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que sujet à l'article 84, il a approuvé le 1er décembre 1971, les règlements généraux (incluant l'article 25 diminuant le nombre de ses administrateurs de 10 à 7) de la corporation « Le Service des Loisirs de Saint Jean-de-Matha de Montréal incorporé », et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Rocu Rioux.44268-0 6154-48 Aéro-Club de St-Hubert St.Hubert Flying Club Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 16 décembre 1971, il a approuvé les règlements généraux de la corporation « Aéro-Club de St-Hubert \u2014 St.Hubert Flying Club », et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44194-0 2507-71 Association des Diplômés M.B.A.(Laval) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que sujet à l'article 84, il a approuvé le 16 décembre 1971, les règlements généraux (incluant un article augmentant le nombre des administrateurs de 3 à 9) de l'« Association des Diplômés M.B.A.(Laval) », et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44196-o 916-71 Les Placements Collectifs inc.Collective Investments Inc.Notice is given that \"Les Placements Collectifs inc.\u2014 Collective Investments Inc.\" has changed the number of its directors from 14 to 5.Jacques V.Goyer, Secretary.44267 12120-56 Le Service des Loisirs de Saint Jean-de-Matha de Montréal incorporé The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, gives notice that under section 84 he approved on December 1st 1971, the general by-laws (including section 25 decreasing the number of its directors from 10 to 7) of the corporation \"Lc Service des Loisirs de Saint Jean-de-Matha de Montréal incorporé\", pursuant to section 225 of the Companies Act.Roch Rioux, Director of the Companies Service.44268 6154-48 Aéro-Club de St-Hubert St.Hubert Flying Club The minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on December 16, 1971, he approved the general by-laws of the corporation \"Aéro-Club de St-Hubert \u2014 St.Hubert Flying Club\", pursuant to section 225 of the Companies Act.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44194 2507-71 Association des Diplômés M.B.A.(Laval) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that under sections 84 he approved on December 16, 1971, the general by-laws (including a section increasing the number of its directors from 3 to 9) of \"Association des Diplômés M.B.A.(Laval)\", pursuant to section 225 of the Companies Act.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44196 916-71 1006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10k' année, n\" k Alimentation Lemelin inc.La compagnie « Alimentation Lemelin inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 6.Le secrétaire, Mme Clezianne M.Lemelin.44195-o 1470-63 Boutique Corinne inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 6, de la compagnie « Le Perruquier de Sherbrooke inc.», constituée par lettres patentes en date du 21e jour de février 1967, changeant son nom en celui de « Boutique Corinne inc.».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44197-0 727-67 Collège Marie de France Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que sujet à l'article 84, il a approuvé le 7 janvier 1972, les règlements généraux (incluant un article augmentant le nombre des administrateurs de S à 11) de la corporation « Collège Marie de France », et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44198-o 3212-39 Les Concours de Musique du Québec inc.Québec Music Competitions Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 37, de la corporation « Les Festivals de Musique du Québec inc.\u2014 Québec Music Festivals Inc.\", constituée par lettres patentes en date du 31e jour d'août 1960.changeant son nom en celui de « Les Concours de Musique du Québec inc.\u2014 Québec Music Competitions Inc.».Le directeur du service des compagnies, s Rocii Rioux.44199-0 13473-60 Côte-Nord Sportif inc.La compagnie « Côte-Nord Sportif inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Paul-André Tremblay.44202-O 3792-71 Club Social de Slc-Maric inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 23 novembre 1971, il a approuvé les règlements généraux de la corporation « Club Social de Ste-Marie inc.», et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Rocu Rioux.44203-O 3940-70 Alimentation Lemelin inc.Notice is given that \"Alimentation lemelin inc.\" bas increased the number of its directors from 3 to 6.44195 Mrs.Clezianne M.Lemelin, Secretary.1470-63 Boutique Corinne inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law No.6, of the company \"Le Perruquier de Sherbrooke inc.\".incorporated by letters patent dated the 21st day of February, 1967, changing its name into that of \"Boutique Corinne inc.\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44197-0 727-67 Collège Marie de France The minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that under section 84 he approved on January 7, 1972, the general by-laws (including a section increasing the number of its directors from 8 to 11) of the corporation \"Collège Marie de France\", pursuant to section 225 of the Companies Act.44198 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.3212-39 Les Concours de Musique du Québec inc.Québec Music Competitions Inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law No.37, of the corporation \"Les Festivals de Musique du Québec inc.\u2014 Québec Music Festivals Inc.\", incorporated by letter?, patent dated the 31st day of August, 1960.changing its name into that of \"Les Concours de Musique du Québec inc.\u2014 Québec Music Competitions Inc.\".Rocu Rioux, Director of the Companies Service.44199-0 13473-60 Côte-Nord Sportif inc.Notice is given that \"Côte-Nord Sportif inc.\" has increased the number of its directors from 3 to 4.14202 Paul-André Tremblât, Secretary.3792-71 Club Social dc Ste-Marie inc.The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice that on November 23, 1971.he approved the general by-laws of the cori>ora-tion \"Club Social de Ste-Marie inc.\", pursuant to section 225 of the Companies Act.Rocii Rioux.,____ Director of the Companies Service.44203 *\" 3940.70 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.k 1067 Conseil de Vie Étudiante du Collège de Chicoutimi inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 1er décembre 1971, il a approuvé le règlement numéro 1 de la corporation « Conseil de Vie Étudiante du Collège de Chicoutimi inc.», et ce, en vertu de l'article 226 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.44200-o 3832-70 Conseil de Vie Étudiante du Collège de Chicoutimi inc.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on December 1, 1971, and pursuant to section 226 of the Companies Act, he approved by-law number 1 of \"Conseil de Vie Étudiante du Collège de Chicoutimi inc.\".Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44200 3832-70 Conseil Régional des Loisirs de Québec Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 29 novembre 1971, il a approuvé l'amendement aux règlements généraux de la corporation « Conseil Régional des Loisirs de Québec », et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Rocu Rioux.44201-o 15880-59 Conseil Régional des Loisirs de Québec The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on November 29, 1971, and pursuant to section 225 of the Companies Act, he approved the amendment to the general by-laws of \"Conseil Régional des Loisirs de Québec\".Rocu Rioux, Director of the Companies Service.44201 15880-59 Limited Patcrnship Services (Montreal) Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies , et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro XXIV, de la compagnie' Domcap Investments Inc.».constituée par lettres patentes en date du 14e jour d'octobre 1970, changeant son nom en celui de « Limited Partnership Services (Montreal) Inc.».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44319-o 4418-70 Réjean Jobin Auto inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement spécial « A » 1971, de la compagnie « Jobin Auto inc.», constituée par lettres patentes en date du 1er jour d'octobre 1968, changeant son nom en celui de « Réjean Jobin Auto inc.».Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.44204-o 4490-68 Michelin Upholstering Ltd.Rembourrage Michelin ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro XIV, de la compagnie « F.Firestone Upholstering Ltd.\u2014 Rembourrage F.Firestone ltée », constituée par lettres patentes en date du 3e jour de juillet 1969, changeant son nom en celui de « Michelin Upholstering Ltd.\u2014 Rembourrage Michelin ltée ».Le directeur du service des compagnies, Rocu Rioux.4207-e 3248-69 Limited Paternship Services (Montreal) Inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law No.XXIV, of the company \"Domcap Investments Inc.\".incorporated by letters paient dated the 14th day of October.1970, changing its name into that of \"Limited Partnership Services (Montreal) Inc.\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44319-0 4418-70 Réjean Jobin Auto inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the special by-law \"A\" 1971, of the company \"Jobin Auto inc.\", incorporated by letters patent dated the' 1st day of October 1968, changing its name into that of \"Réjean Jobin Auto inc.\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.44204-o 4490-68 Michelin Upholstering Ltd.Rembourrage Michelin ltée Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law No.XIV, of the company \"F.Firestone Upholstering Ltd.\u2014 Rembourrage F.Firestone ltée\", incorporated by letters patent dated the 3rd day of July, 1969, changing its name into that of \"Michelin Upholstering Ltd.\u2014 Rembourrage Michelin ltée\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.44207-o 3248-69 li ins GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° A Les Industries Larco ltée Larro Industries Ltd.La compagnie « Les Industries Larco liée \u2014 Larco Industries Ltd.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, J.Rene Pregent.44205-o 1514-68 Mirage St-liyacinthe inc.La compagnie « Mirage St-Hyacinthe inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 6.Le secrétaire, Réal Laçasse.44208 2317-69 .Mobilier Vie-Line inc.Vic-Line Furniture Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 3, de la compagnie « Lydrak inc.», constituée par lettres patentes en date du 3c jour de juin 1969, changeant son nom en celui de « Mobilier Vic-Line inc.\u2014 Vic-Line Furniture Inc.».Le directeur du service des compagnies, Rocu Rioux.44209-o 2042-69 Les Industries larco ltée Larco Industries Ltd.Notice is given that \"Les Industries Larco ltée \u2014 Larco Industries Ltd.\" bas increased the numl>er of its directors from 3 to 4.J.Rene Precent, Secretary.44205 1514-68 Mirage St-Hyacintbe inc.Notice is given that \"Mirage St-Hyacinthe inc.\" has changed the number of its directors from 3 to 6.44208-o Real Laçasse, Secretary.2317-09 Mobilier Vic-Line inc.Vic-Line Furniture Inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law number 3, of the company \"Lydrak inc.\", incorporated by letters patent dated the 3rd day of June 1969, changing its name into that of \"Mobilier Vic-Line inc.\u2014 Vic-Line Furniture Inc.\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.44209-o 2042-69 Les Productions Librefilms inc.La compagnie « Les Productions Librefilms inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.Le président, Luc-Michel Hannaux.44210-o 624-71 Les Productions Librefilms inc.Notice is given that \"Les Productions Librefilms inc.\" has increased the number of its directors from 3 to 5.Luc-Michel Hannaux, Préside»!*.44210 624-71 L'Union Théâtrale de Sherbrooke inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 16 décembre 1971, il a approuvé les règlements généraux de la corporation « L'Union Théâtrale de Sherbrooke inc.», et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44211-0 2276-71 The United Services Club Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 7 janvier 1972, il a approuvé les règlements numéros 1 à 29 de la corporation « The United Services Club Ltd.», et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.44212-0 5221-68 L'Union Théâtrale de Sherbrooke inc.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on December 16, 1971, he approved the general by-laws of the corporation \"L'Union Théâtrale de Sherbrooke inc.\", pursuant to section 225 of the Companies Act.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44211 2276-71 The United Services Club Ltd.The Minister of Financial Institutions, Companies and Coo|Kratives gives notice that on January 7, 1972, and pursuant to section 225 of the Companies Act, he approved by-laws 1 to 29 of \"The United Services Club Ltd.\" Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44212 5221-68 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1069 Loman Inc.La compagnie « Loman Inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 6.Le secrétaire, A.Lapierre.44206-O 560-70 I uni,m Inc.Notice is given that \"Loman Inc.\" has increased the number of its directors from 3 to 6.A.Lapierre, Secretary.44206 560-70 Sièges sociaux Head Offices Telcmonde Inc.Avis est donné que la compagnie « Telemonde Inc.» constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes octroyées le 27 juillet 1962, et ayant son bureau principal au 1236, rue Crescent, Montréal, province de Québec, a transporté son bureau au 4274, avenue Papineau, dans la ville de Montréal, district de Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 6e jour de décembre 1971.Le président, Pierre Péladeau.13172-62 (Sceau) 44232-o Bernard St-Jean inc.Avis est donné que la compagnie « Bernard St-Jean inc.» constituée en corporation par lettres patentes en date du 4'décembre 1970 et ayant son siège social à Saint-Charles de Lachenaie, a établi son bureau au numéro 147 de la rue St-Jean.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à l'Assomption, ce 14e jour d'avril 1971.Le procureur de la compagnie, Bertrand Allard, notaire.5277-70 44228-0 Saniaro Trade Corporation La compagnie « Samaro Trade Corporation » donne avis qu'elle a transporté son siège social de 1374 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, à4115oucst, rue Sherbrooke, Westmount.Le secrétaire, 3.Salzberger.44229 12140-61 Aqua Maintenance Inc.La compagnie « Aqua Maintenance Inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 3150, rue St-Zotique est, Montréal, au numéro 6117, rue des Préaux, St-Léonard.Le secrétaire, Guy Brulotte.44213-0 715415 Telemonde Inc.Notice is hereby given that \"Telemonde Inc.\", incorporated by letters patent granted under the provisions of Part I of the Companies Act, on July 27, 1962, and having its head office at 1236 Crescent Street, Montreal, Province of Québec, has transferred its head office to 4274 Papineau Avenue, in the City of Montreal, district of Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered as being the head office of the company.Given at Montreal, this 6th day of December, 1972.(Seal) 44232 Pierre Péladeau, President.13172-62 Bernard St-Jean inc.Notice is given that \"Bernard St-Jean inc.\" incorporated by letters patent on December 4, 1970, and having its head office in St.Charles de Lachenaie, has established its office at number 147 St.Jean Street.From the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at l'Assomption, this 14th day of April, 1971.Bertrand Allard, Notary, Attorney for the Company.44228 5277-70 Samaro Trade Corporation Notice is given that \"Samaro Trade Corporation\" has transferred its head office from 1374 Sherbrooke Street West, Montreal to 4115 Sherbrooke Street West, Westmount.J.Salzberger, Secretary.44229-0 12140-61 Aqua Maintenance Inc.Notice is given that \"Aqua Maintenance Inc.\", has transferred its head office from 3150 St-Zotique Street East, Montreal to 6117 des Préaux Street, St-Léonard.44213 Guy Brulotte, Secretary.715415 1070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10k' année, n° k Sheff, Weiser and Associates Inc.Sheff, weiser et associes inc.La compagnie « Slicff, Weiser and Associates Inc.\u2014 Sheff, Weiser et associés inc.» constituée en corporation par lettres patentes datées du 15e jour de novembre 1971, et ayant son siège social à Montréal, au 5165, chemin de la Reine Marie, où son bureau était situé jusqu'à ce jour, donne avis qu'elle l'a transporté au 4560, rue Stanley Weir, Montréal, P.Q.À compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 13e jour de décembre 1971.(Sceau) Joseph A.Weiser.44230 71-6168 Les Arts Valmont ltée Avis est donné que la compagnie « Les Arts Valmont ltée » constituée en corporation par lettres patentes datées du 27 octobre 1971 et ayant son siège social à Kirkland, a établi son- bureau au numéro 16901, Blvd Hymus, Kirkland, province de Québec.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Signé à Cité Lasalle.le 10 décembre 1971.Camille Racicot.44214-0 71-5873 Sheff, Weiser and Associates Inc.Sheff, Weiser et associés inc.Notice is hereby given that \"Sheff, Weiser and Associates Inc.\u2014 Sheff, Weiser et associés inc.\" incorporated by letters patent dated November 15th, 1971 and having its head office in Montreal at 5165 Queen Mary Road, where its office was situated up to today, has moved it to: 4560 Stanley Weir Street, Montreal, P.Q.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 13th day of December, 1971.(Seal) Joseph A.Weiser, 44230-o 71-6168 Les Arts Valmont ltée Notice is given that \"Les Arts Valmont ltée\" incorporated by letters patent dated October 27, 1971, and having its head office in Kirkland, has established its office at number 16901 Hymus Boulevard, Kirkland, Province of Québec.From the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Signed at Lasalle city, December 10, 1971.Camille Racicot.44214 71-5873 Bélanger, Philibert & Sénécal inc.Avis est donné que la compagnie « Bélanger, Philibert & Sénécal inc.» constituée en corporation par lettres patentes émises en date du 30e jour d'août 1971, et ayant son siège social dans la ville d'Anjou, y a établi l'endroit de son siège social au numéro 8001.Boulevard Les Galeries d'Anjou.A compter de la date du présent avis, l'adresse ci-dessus est considérée par la compagnie comme étant l'endroit de son siège social.Donné à Montréal, ce 2e jour de décembre 1971.Le président, Jacques Philibert.44215-0 71-4682 Les Vins Chantcclcr limitée Chanteclcr Wines Limited La compagnie « Les Vins Chantecler limitée \u2014 Chanteclcr Wines Limited » constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes datées du 24 mars 1971, donne avis qu'elle a transporté son siège social du local 2260, 630, ouest, boulevard Dorchester, en la ville de Montréal, au local 606, 1808 ouest, rue Sherbrooke, en la ville de Montréal.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Montréal, 10 décembre 1971.(Sceau) L'assistant secrétaire, D.T.Dingle.44216 1312-71 Bélanger, Philibert & Sénécal inc.Notice is given that \"Bélanger.Philibert & Sénécal inc.\", incorporated by letters patent issued on the 30th day of August.1971, and having its head office in the town of Anjou, has established its head office therein at number 8001 Les Galeries d'Anjou Boulevard.From the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 2nd day of December, 1971.Jacques Philibert, President.44215 71-4682 Les Vins Chantecler limitée Chantecler Wines Limited Notice is hereby given that \"Les Vins Chanteclcr limitée \u2014 Chantecler Wines Limited\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated March 24, 1971, has moved its head office from Suite 2260, 630 Dorchester Boulevard West in the City of Montreal to Suite 606, 1S08 Sherbrooke Street West in the City of Montreal.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Montreal, December 10*, 1971. D.T.Dingle, Assistant Secretary.44216-0 1312.71 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 39, 1973, Vol.104, No.4 1071 Les Constructions Jean-P.Haniclin Inc.Avis est donné que la compagnie « Les Constructions Jean-P.Hamclin Inc.» constituée en corporation dans la province de Québec, par lettres patentes, accordées en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, en date du 23 septembre 1971 et ayant son bureau principal, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières.Province de Québec, a établi son bureau à 5380 rue Nantes, Trois-Rivières Ouest.À compter de la date du présent avis ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Signé à Trois-Rivières Ouest, ce Se jour de décembre 1971.Le président, Jean-P.Hamelin.44217-0 71-4980 Melri Inc.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Melri Inc.», constituée en corporation par lettres patentes émises par le gouvememei t du Québec en date du 21 décembre 1970.et ayant son siège social à Sorel, dans le district de Richelieu, a établi son principal bureau d'affaires au No 235C, du boulevard Fiset, à Sorel.A compté du présent avis, ce bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Sorel, ce 10 décembre 1971.Le président, Robert Hamel.5658-70 44224-0 Papineau Machine Shop Inc.Avis est par les présentes donne que la compagnie « Papineau Machine Shop Inc.», constituée en corporation par lettres patentes émises en date du 25 octobre 1965, en vertu de la première partie de la Loi des compagnies du Québec et ayant son siège social à Montréal, a établi son siège social au 7912,16e Avenue, St-Michel, Montréal, district de Montréal.A compter de la date des présentes, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social et sa principale place d'affaires.Donné à Montréal, ce 13 décembre 1971.(Sceau) Le président, Guy Bisutti.44225-0 4702-65 Les Constructions Jean-P.Hamelin Inc.Notice is given that company \"Les Constructions Jean-P.Hamelin Inc.\" incorporated by letters patent under Part I of the Companies Act ol Québec, dated September 23, 1971, and having its head office at Trois-Rivières Ouest, Province of Québec, has established its office at 5380 Nantes Street, Trois-Rivières Ouest.From the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Signed at Trois-Rivières Ouest, this 8th day of December, 1971.Jean-P.Hamelin, President.44217-0 71-4980 Melri Inc.Notice is hereby given that the company \"Melri Inc.\", incorporated by letters patent dated December 21, 1970 and having its head office at Sorel, in the district of Richelieu, has established this said office at 235C, Fiset Boulevard, Sorel.From and after the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Sorel, December 10, 1971.Robert Hamel, President.44224-o 5658-70 Papineau Machine Shop Inc.Notice is hereby given that \"Papineau Machine Shop Inc.\".a company incorporated by letters patent issued on October 25, 1965.under the provisions of Part I of the Québec Companies Act, and having its head office in Montreal, has established its head office at 7912, 16th Avenue, St.Michel, Montreal, district of Montreal.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being the head office and principal place of business of said company.Dated at Montreal, this December 13, 1971.(Seal) 44225-0 Guy Bisutti, President.4702-65 Le Perruquier de Sherbrooke inc.La compagnie « Le Perruquier de Sherbrooke inc.», donne avis qu'elle a changé son siège social de Montréal au numéro 95 sud, rue Wellington, Sherbrooke.Le secrétaire, Lucette Tremblay.44226-o 727-67 Le Perruquier de Sherbrooke inc.Notice is given that \"Le Perruquier de Sherbrooke inc.\" has transferred its head office from Montrea) to 95 Wellington Street South, Sherbrooke.Lucette Tremblay.Secretary.44226 727-67 1072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101' année, n° i Lacombe et frère inc.Avis est donne que la compagnie « Lacombe et frère inc.», constituée en corporation par lettres patentes en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, le 22 novembre 1971 et ayant son siège social à Grand'Mère, a établi son bureau au 891, 6e Avenue à Grand'Mère, district de St-Maurice, dans la province de Québec.Signé à Grand'Mère, ce 7e jour de décembre 1971.44223-0 Le secrétaire, Marcel Lacombe.71-5569 G.Proulx et associés, assurances inc.Avis est donné que la compagnie « G.Proulx et associés, assurances inc.», constituée en corporation par lettres patentes en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, le 8 octobre 1971 et ayant son siège social à Laval, a établi son bureau au 192, boul.Cartier, Laval des Rapides, Ville de Laval, district de Montréal, dans la province de Québec.Signé à Grand'Mère, ce 2e jour de décembre 1971.Le secrétaire, François Blais.44227-0 71-5334 Cody-Chargo ltée Cody-Chargo Ltd.Avis est donné que la compagnie « Cody-Chargo ltée \u2014 Cody-Chargo Ltd.» constituée en corporation sous l'autorité de la première partie de la Loi des compagnies (Québec) par lettres patentes du 2 novembre 1970, et ayant son siège social à 148, Sedgefield, Pointe Claire, l'a transporté au numéro 100, Yonge Crescent, Pointe Cla ire, province de Québec. compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Pointe Claire, ce 15c jour de septembre 1971.44270-o Le président, J.M.Cody.4879-70 Multi-Services Professionnels (M.S.P.) Inc.Avis est donné que la compagnie « Multi-Services Professionnels (M.S.P.) Inc.» constituée en corporation dans la province de Québec par lettres patentes accordées le 15 février 1971 et ayant son siège social dans la ville d'Outremont où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au 22, rue St-Cyrille l'a transporté au 525., de la rue Stuart.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Outremont, ce 25 novembre 1971.(Sceau) La secrétaire, Yolande R.Pelletier.44271-0 731-71 Lacombe et frère inc.Notice is hereby given that \"Lacombe et frère inc.\", incorporated by letters patent under the provisions of Part I of the Companies Act, on the Novmber 22, 1971 and having its head office in Grand'Mère, has established its office at 891, 6e Avenue.'in Grand'Mère, district of St-Maurice, Province of Québec.Dated at Grand'Mère, this 7th day of December 1971.Marcel Lacombe, Secretary.44223-0 71-5569 C.Proulx et associés, assurances inc.Notice is given that \"G.Proulx et associés, assurances inc.\", incorporated by letters patent under the provisions of Part I of the Companies Act, on the October 8, 1971 and having its head office at Laval, has established its office at 192, boul.Cartier, Laval des Rapides, Ville de Laval, district of Montreal, Province of Québec.Dated at Grand'Mère, this 2nd day of December 1971.François Blais, Secretary.44227-0 71-5334 Cody-Chargo Ltd.Cody-Chargo ltée Notice is hereby given that \"Cody-Chargo Ltd.\u2014 Cody-Chargo ltée\", a company incorporated under the Québec Companies Act, by letters patent dated November 2, 1970 and having its head office at 148 Sedgefield, Pointe Claire, Province of Québec, has moved it so 100 Yonge Crescent, Pointe Claire, Province of Québec.From the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Signed at Pointe Claire, this 15th dav of September, 1971.J.M.Cody, President.44270-o 4879-70 Multi-Services Professionnels (M.S.P.) Inc.Notice is given that \"Multi-Services Professionnels (M.S.P.) Inc.\" incorporated in the Province of Québec, by letters patent issued on February 15.1971, and having its head office in the town of Outrcmont, where its office was situated up to to-day, at 22 St.Cyrille Street, has moved it to 525 Stuart Street.From the date of this notice the said office is considered by the company as being its head office.Given in Outremont, November 25, 1971.(Seal) Yolande R.Pelletier, Secretary.44271 73t71 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 39, 1972, Vol.104, No.4 1073 L'Opéra du Québec Avis est par la présente donné que « L'Opéra du Québec » a été constitué en corporation par lettres patentes émises par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, en date du 30 décembre 1970, et ayant son siège social et sa principale place d'affaires à Montréal, a établi son bureau au numéro 222, boulevard Saint-Laurent.À compter du présent avis, ce bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 21e jour de décembre 1971.(Sceau) 44272-0 Le secrétaire, Robert Alain.5650-70 Varie Inc.Avis est donné que la compagnie « Varie Inc.» constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 juillet 1968 et ayant son siège social dans la cité de St-Jean où elle avait son bureau situé jusqu'à aujourd'hui au 112 de la rue St-Jacques à St-Jean, l'a transporté au numéro 123 de la rue St-Jacques, C.P.304, St-Jean.À compter du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à St-Jean, ce 5e jour de janvier 1972.Le secrétaire, Jacques Rancourt.44273-0 3141-68 Côte-Nord Sportif Inc.Avis est donné que la compagnie « Côte-Nord Sportif Inc., constituée en corporation sous la première partie de la Loi des compagnies de Québec, par le ministre des institutions financières/compagnies et coopératives du Québec, en date du 16 juillet 1971, et ayant son siège social à Haute-Rive, a établi son bureau au numéro 1704, de l'avenue Pottier à Hauterive, comté de Saguenay.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Hauterive, ce 7e jour de décembre 1971.Le président, André Benoit.44218-0 3792-71 École de formation sportive Grand-Mère inc.Avis est donné que la compagnie « École de formation sportive Grand'Mère inc.», constituée en corporation par lettres patentes en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lie jour de juin 1971, et ayant son siège social à Grand'Mère, a établi son bureau au 653, 6e rue à Grand'Mère, district de Saint-Maurice, dans la province de Québec.Daté à Shawinigan, ce 15e jour de décembre 1971.44219-o Le secrétaire, Jean-Paul Brouillette.3155-71 L'Opéra du Québec Notice is hereby biven that \"L'Opéra du Québec\" incorporated by letters patent dated December 30, 1970 and having its head office in Montreal, has located its head office in the city of Montreal, at 222 St.Laurent Boulevard.From and after the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Montreal, Province of Québec, this 21st day of December, 1971.(Seal) Robert Alain, Secretary.44272-0 \u2022 5650-70 Varie Inc.Notice is given that \"Varie Inc.\" incorporated by letters patent of the Province of Québec, dated July 24, 1968, with a head office situated at number 112 St-Jacques Street, in the city of St-Jean, has transferred the said head office to number 123 St-Jacques Street, C.P.304, St-Jean.From and after the present notice, the said office shall be consideied by the company as being its head office.Given at St-Jean, this 5th day of January, 1972.Jacques Rancourt, Secretary.44273-0 3141-68 Côte-Nord Sportif Inc.Notice is hereby given that the company \"Côte-Nord Sportif Inc.\", incorporated under Part I on the Québec Companies at by letters patent bearing date the July 16, 1971, issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of Québec, and having its head office in Haute-Rive, has established its office at number 1704, Pottier Street, in the City of Hauterive, County of Saguenay.From and after the date this notive, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Given at Hauterive, this 7th day of December 1971.André Benoit, President.44218-0 3792-71 École de formation sportive Grand-Mère inc.Notice is given that \"École de formation sportive Grand'Mère inc.\", incorporated by letters patent under the provisions of Part III of the Companies Act, on the 11th day of December 1971, and having its head office in Grand'Mère, has established its office at 653, 6e rue, Grand'Mère, in district of St-Maurice, Province of Québec.Dated at Shawinigan, this 15th day of December 1971.Jean-Paul Brouillette, Secretary.44219-0 3155-71 1074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1912, 10V année, n° i Productions émotion inc.Emotion Productions Inc.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Productions émotion inc.\u2014 Emotion Productions Inc.», constituée en corporation dans la province de Québec, en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes portant la date du 27 septembre 1971 et ayant son siège social en la ville de Montréal, a établi son bureau principal au 4825 ouest, de la rue Ste-Catherine, Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Montréal, ce premier jour d'octobre 1971.(Sceau) Le président, François Dallecret.44220-o 71-5136 lnfosileni inc.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Infosilcm inc.», constituée en corporation dans la province de Québec, en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes portant la date du 7 septembre 1971 et ayant son siège social en la ville de Montréal, a établi son bureau principal au 4820 avenue Wilson, Montréal 260, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Montréal, ce 7e jour de septembre 1971.Le président, (Sceau) Jacques Mélis.4422 l-o 71-4326 Joly Construction Inc.Avis est par les présentes, donné que la compagnie « Joly Construction Inc.», constituée en corporation par lettres patentes émises le 17 juin 1971 en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Tracy, a établi son bureau au no 5575, de la route Maric-Victorin.À compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Tracy, ce 1er jour de septembre 1971.Le secrétaire, (Sceau) Serge Joly.44222-q 3290-71 Productions émotion inc.Emotion Productions Inc.Notice is hereby given that the company \"Production! émotion inc.\u2014 Emotion Productions Inc.\", incorporated in the Province of Québec, under Part I of the Companies Act, by letters patent bearing the date of September 27, 1971, and having its head office in the city of Montreal, has established its office at 4825 Ste-Catherine Street, West, Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Montreal, this 1st day of October 1971.François Dali.egret, (Seal) President.44220-o 71-5136 I n lu-11' in inc.Notice is hereby given that the company \"Infosilcm inc.\", incorporated in the Province of Québec, under Part I of the Companies Act.by letters patent bearing the date of September 7, 1971.and having its head office in the city of Montreal, has established its office at 4820 Wilson Avenue, Montreal 260.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Montreal, this 7th day of September 1971.Jacques Mêlis, (Seal) President.4422 l-o 71-4326 Joly Construction Inc.Notice is hereby given that \"Joly Construction Inc.\", incorporated by letters patent under the provisions of the Part I of the Companies Act.on the June 17, 1971, and having its head office at Tracy, has established its office at 5575.Marie-Vietorin Road.From and after the date of this notice, the said office will be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Tracy, this 1st day of September 1971.Serce Joly, (Seal) Secretary.44222-o 3290-71 Avis d'annulation de Letters Patent lettres patentes Notice of annulment Glendale Industries Ltd.Glendalc IiHustries Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies The Minister of Financial Institutions, Companies et coopératives donne avis à « Glendale Industries and Cooperatives hereby gives notice to \"Glendalc LUI.», constituée en corporation par lettres patentes Industries Ltd.\", incorporated by letters patent under sous l'autorité de la première partie de la Loi des com- Part I of the Companies Act on August 21.1902: pagnies en date du 21 ao\\1t 1962: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1075 a) qu'elle a omis de produire le rapport prescrit par l'article 4 de la Loi des renseignements sur les compagnies (chapitre 273) pour les années 1968 à 1971 inclusivement.b) et qu'en conséquence, faute par elle d'avoir fourni ledit rapport pour lesdites années tel que prescrit par la loi et de payer les droits exigibles dans les 60 jours la publication dudit avis, il entend procéder à l'annulation de la charte de ladite compagnie en vertu des articles 24 et 25 de la Loi des compagnies.44178-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.13478-62 (a) that it has failed to file a return for the years 1968 to 1971 inclusive, as prescribed by section 4 of the Companies Information Act (Chapter 273) ; (6) therefore, as prescribed by law, upon default of the company to file the said return for the above-mentioned years and upon its failure to pay the required duties within sixty days upon the publication of this notice, it is the intention of the Minister to annul the charter of the said company, pursuant to sections 24 and 25 of the Companies Act.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 13478-62 Valleyfield Adjustment Bureau Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis à « Valleyfield Adjustment Bureau Ltd.», constituée en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la première partie de la Loi des compagnies en date du 20 mars 1964: a) qu'elle a omis de produire le rapport prescrit par l'article 4 de la Loi des renseignements sur les compagnies (chapitre 273) pour les années 1964 et 1966 à 1971 inclusivement.6) et qu'en conséquence, faute par elle d'avoir fourni ledit rapport pour lesdites années tel que prescrit par la loi et de payer les droits exigibles dans les 60 jours de la publication dudit avis, il entend procéder à l'annulation de la charte de ladite compagnie en vertu des articles 24 et 25 de la Loi des compagnies.44178-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.1285-64 Valleyfield Adjustment Bureau Ltd.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice to \"Valleyfield Adjustment Bureau Ltd.\", incorporated by letters patent under Part I of the Companies Act on March 20, 1964, (a) that it has failed to file a return for the years 1964 and 1966 to 1971 inclusive, as prescribed by section 4 of the Companies Information Act (Chapter 273).(6) therefore, upon default of the company to file the said return for the above-mentioned years as prescribed by law and upon its failure to pay the required duties within sixty days from the publication of this notice, it is the intention of the Minister to annul the charter of the said company, pursuant to sections 24 and 25 of the Companies Act.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.44178 1285-64 Compagnies étrangères Siège social Extra-Provincial Companies Head Office Ideal Bay Explorations Limited Avis est donné que selon une nouvelle procuration en date du 6e jour de décembre 1971, dont une copie a été transmise au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, le bureau principal dans la province de Québec de « Ideal Bay Explorations Limited », une compagnie dûment autorisée à exercer son commerce dans ladite province, en vertu de la Loi des compagnies étrangères, a été transporté de 10, ouest, rue St-Jacques, local 1003, Montréal, à 800 ouest, boulevard Dorchester, local 2610, Montréal, district judiciaire de Montréal.M.Guy E.Boisvert de Boisvert & Pickel, 800 ouest, boulevard Dorchester, Montréal, demeure l'agent principal de ladite compagnie dans la province de Québec.Le sous-minist re des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44180 4-70 Ideal Bay Explorations Limited Notice is given that, by new Power of Attorney, dated the 6th day of December, 1971, a copy of which has been transmitted to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the principal office in the Province of Québec of \"Ideal Bay Explorations Limited\", a company duly authorized to carry on business in the said province, in virtue of the Extra-Provincial Companies Act, has been changed from 10 St.James Street West, Suite 1003, Montreal to 800 Dorchester Boulevard West, suite 2610, Montreal, judicial District of Montreal.Mr.Guy E.Boisvert of Boisvert & Pickel, 800 Dorchester Boulevard West, Montreal, remains the chief agent of the said company in the Province of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44180-o 4-70 1076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10k' année, n\" k Compagnies étrangères Agent Extra-Provincial Companies Agent Trans-American Collections, Inc.Avis est donné que, selon une nouvelle procuration en date du 6 décembre 1971, dont une copie a été transmise au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, C.T.Corporation System (Canada), Ltd., 55, d'Autcuil, Québec, a été nommée aux fins de remplacer M.C.Antoine Geoffrion, à titre d'agent principal dans la province de « Trans-American Collections, Inc.», une compagnie dûment autorisée à exercer des affaires dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies étrangères.Avis est aussi donné que conformément à la nouvelle procuration ci-haut mentionnée, le siège social de ladite compagnie est établie au 55, d'Auteuil, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44181 Trans-American Collections, Inc.Notice is given that, by new power of attorney dated December 6, 1971, a copy of which was sent to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, C.T.Corporation System (Canada), Ltd., 55 d'Auteuil, Québec, was appointed to replace Mr.C.Antoine Geoffrion, as chief agent in the Province of \"Trans-American Collections, Inc.\", an Extra-Provincial Company duly authorized to carry on business in the Province of Québec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act.Notice is also given that pursuant to the above-mentioned new power of attorney, the head office of the said company is established at 55 d'Autcuil, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.72-71 44181-0 72-71 Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Union La Caisse Populaire Desjardins de Beloeil (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 21 septembre 1971, par « La Caisse Populaire Desjardins de Beloeil >', modifiant son territoire qui était « la ville de Beloeil», en y ajoutant « la ville de McMastervilIe ».Québec, le 12 janvier 1972.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralives, 44242-0 Ls-Philippe Bouchard.La Caisse Populaire de Louiseville (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 16 juin 1971, par « La Caisse Populaire de Louiseville», modifiant son terriloire qui était « Louiseville (ville et paroisse) », en y ajoutant « la paroisse St-Léon-le-Grand, comté de Maskinongé ».Québec, le 12 janvier 1972.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 44243-0 Ls-Phiuppe Bouchard.44242 La Caisse Populaire Desjardins de Beloeil (Savings and Credit Unions Ad) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives approved the by-law passed on September 21, 1971, by \"La Caisse Populaire Desjardins de Beloeil\", altering its territory which was \"the Town of Beloeil\", by adding \"the Town of McMastervilIe\" thereto.Québec, January 12, 1972.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.La Caisse Populaire de Louiseville (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives approved the by-law passed on June 16, 1971, by \"La Caisse Populaire de Louiseville\" altering its territory which was \"Louiseville (Town and Parish)\", by adding \"the Parish of St.Leon-le-Grand, County of Maskinongé\", thereto.Québec, January 12, 1972.44243 Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.k 1077 Ministère des institutions Department of Financial financières, compagnies et Institutions, Companies and coopératives Cooperatives Assurance Insurance La Stabilité, Compagnie d'Assurance-Vie Stability Life Insurance Company Avis de demande de remise des valeurs Avis est donné, par les présentes, que « La Stabilité, Compagnie d'Àssurancc-Vie \u2014 Stability Life Insurance Company», constituée en corporation par lettres patentes, conformément aux articles 2 et suivants de la Loi des assurances (S.R.Q.1964, chapitre 295), a réassuré toutes les obligations découlant de ses contrats d'assurances en vigueur dans la province de Québec au 22 novembre 1968 auprès de La Laurentien-ne.Compagnie Mutuelle d'Assurance, constituée en corporation par la Loi 7-8, Elizabeth II, chapitre 185, et 10-11, Elizabeth II, chapitre 90, enregistrée dans la province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil le 1er mai 1972 pour obtenir la remise de ses valeurs déposées chez le ministre des Finances de la province de Québec.Avis est de plus donné que tous les réclamants actuels ou éventuels, s'opposant à la remise des valeurs de la compagnie « La Stabilité, Compagnie d'Assurance-Vie \u2014 Stability Life Insurance Company », constituée en corporation par lettres patentes, conformément aux articles 2 et suivants de la Loi des assurances (S.R.Q.1964, chapitre 295), doivent produire leur opposition à l'Inspecteur des Assurances (Surintendant des assurances).Service des assurances, Hôtel du Gouvernement, Québec, le ou avant le 1er mai 1972.Donné à Hull, province de Québec, ce 13 janvier 1972.Le liquidateur, 8, rue Décosse Jules Joly.Hull, P.Q.44240-o Association coopérative Association coopérative forestière de St-Alphonse (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la demande du syndicat coopératif « Syndicat agricole forestier de St-Alphonsé », de cesser d'être régi par la Loi des syndicats coopératifs et de devenir une association régie par la Loi des associations coopératives, sous le nom de « Association coopérative forestière de St-Alphonse ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralives, 44241-0 Ls-Philippe Bouchard.La Stabilité, Compagnie d'Assurance-Vie Stability Life Insurance Company Notice of application for return of securities Notice is hereby given that \"La Stabilité, Compagnie d'Assurance-Vie \u2014 Stability Life Insurance Company\", incorporated by letters patent, in virtue of section 2 and following of the Insurance Act (R.S.Q., 1964, Chapter 295), has reinsured all its obligations arising out of its insurance contracts in force in the Province of Québec on the November 22, 1968 with La Laurentienne, Compagnie Mutuelle d'Assurance, incorporated by the Act 7-8, Elizabeth II, Chapter 1S5, and 10-11, Elizabeth LI, Chapter 90, registered in the Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council on the 1st of May 1972 for the release of its securities deposited with the Minister of Finance of the Province of Québec.Notice is hereby given furthermore that all claimants, actual or eventual, opposing the release of the securities of the company \"La Stabilité, Compagnie d'Assurance-Vie\u2014Stability Life Insurance Company\", incorporated by letters patent, in virtue of section 2 and following of the Insurance Act (R.S.Q., 1964, Chapter 295), must file their opposition with the Inspector of Insurance (Superintendent of Insurance), Department of Insurance, Government House, Québec, on or before the 1st of May 1972.Given at Hull, Province of Québec, this January 13, 1972.Jules Joly, 8, Décosse Street, Liquidator.Hull, P.Q.44240-o Cooperative Association Association coopérative forestière de St-Alphonse (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the application of the cooperative syndicate \"Syndicat agricole forestier de St-Alphonse\", to cease to be governed by the Cooperative Syndicates Act and to become an association governed by the Cooperative Associations Act, under the name of \"Association coopérative forestière de St-Alphonse\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 44241 Companies and Cooperatives. 1078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101' année, n\" 4 Commission municipale du Québec Québec Municipal Commission Avis public Avis est par les présentes donné que la Commission municipale du Québec, à sa séance en date du 24 janvier 1972, a adopté la résolution suivante: « Il est résolu que, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Loi de la Commission municipale (S.R.Q.1964, ch.170), les corporations ci-après mentionnées ne soient plus, à compter du 5 février 1972, considérées comme étant en défaut au sens de la section V de ladite Loi: » Comté Ville de Bagotville Saint-Henri-de-Taillon Village de St-Jérôme Ville de Ste-Geneviève Québec, le 24 janvier 1972.44283-0 Chicoutimi Lac St-Jean-Est Lac St-Jean-Est Ile-dc-Montréal Le secrétaire, Roger Desaulniers.Public notice Notice is hereby given that the Québec Municipal Commission has adopted the following resolution at its sitting of January 24, 1972: \"Resolved that in accordance with the provisions of Section 52 of the Municipal Commission Act (R.S.Q.1964, C.170), from and after February 5, 1972, the corporation named hereunder shall no longer be considered in default within the meaning of Division V of the said act;\" Town of Bagotville Saint-IIenri-de-Taillon Village of St-Jérôme Town of Ste-Geneviève Québec, January 24, 1972.Roger Desaulniers, 44283-0 Secretary.County Chicoutimi Lac St-Jean-Est Lac St-Jean-Est Ile-de-Montréal Liquidation \u2014 Loi de la Comptoir Avicole de Saint-Félix de Valois (Loi des sociétés coopératives agricoles) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de la société 'coopérative agricole «Comptoir Avicole de Saint-Félix de Valois», tenue à St-Félix de Valois, dans le district électoral de Joliette, le 20 décembre 1971, il a été résolu de liquider la coopérative, conformément aux dispositions de la Loi des sociétés coopératives agricoles et de la Loi des sociétés coopératives agricoles et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que MM.René Allard, Joachim Girard et Germain Dufresne soient nommés liquidateurs.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 44244-0 Ls-Philippe Bouchard.Magasin Co-op de Trinité-des-Monts (Lot des associations coopératives) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de l'association coopérative «Magasin Co-op de Trinité-des-Monts», tenue à Trinité-des-Monts, dans le district électoral de Rimouski, le 9 novembre 1971, il a été résolu que les affaires de cette association coopérative soient liquidées et que celle-ci soit dissoute en vertu des dispositions de la Loi des associations coopératives et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que MM.Viateur Ouellet, René Castonguay et Donald Michaud soient nommés liquidateurs.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 44245-0 Ls-Philippe Bouchard.Winding \u2014 Up Act Comptoir Avicole de Saint-Félix de Valois (Cooperative Agricultural Associations Act) Notice is given that at a special general meeting of the members of the cooperative agricultural association \"Comptoir Avicole de Saint-Félix de Valois\", held at St.Félix de Valois, in the electoral district of Joliette, on December 20, 1971, it was resolved to wind-up the cooperative, in conformity with the provisions of the Cooperative Agricultural Associations Act and the VVinding-Up Act, and that Messrs.René Allard, Joachim Girard and Germain Dufresne be appointed liquidators.Ls-Philippe Bouchahd, Deputy Minister of Financial Institutions, 44244 Companies and Cooperatives.Magasin Co-op de Trinité-des-Monts (Cooperative Associations Act) Notice is given that at a special general meeting of the members of the cooperative association \"Magasin Co-op de Trinité-des-Monts\", held at Trinité-des-Monts, in the electoral district of Rimouski, on November, 9, 1971, it was resolved that the affairs of this cooperative association be wound up and that it be dissolved, pursuant to the provisions of the Cooperative Associations Act and the W'inding-Up Act, and that Messrs.Viateur Ouellet, René Castonguay and Donald Michaud be appointed liquidators.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 44245 Companies and Cooperatives. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10i, No.i 1079 Société coopérative agricole de St-Michel de Squateck (Loi des sociétés coopêiativcs agricoles) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de la « Société coopérative agricole de St-Michel de Squateck », tenue à St-Michel de Squateck, dans le district électoral de Témiscouata, le 17 décembre 1971, il a été résolu de liquider la coopérative, conformément aux dispositions de la Loi des société coopératives agricoles et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que MM.Philippe Lebel, Albert Dumont et Polydore Morneau soient nommés liquidateurs.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.44246-0 Ls-Philitpe Bouchard.Société coopérative agricole de St-Michel de Squateck (Cooperative Agricultural Association Ad) Notice is given that at a special general meeting of the members of the \"Société coopérative agricole de St-Michel de Squateck\", held at St.Michel de Squateck, in the electoral district of Témiscouata, on December 17, 1971, at was resolved to wind-up the cooperative, in conformity with the provisions of the Cooperative Agricultural Associations Act and the Windung-Up Act, and that Messrs.Philippe Lebel, Albert Dumont and Polydore Morneau be appointed liquidators.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 44246 Companies and Cooperatives.Syndicats professionnels Professional Syndicates Fédération du Commerce inc.(CSN) (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives dorme avis que le 2 février 1971, il a autorisé le changement de nom de « Fédération Nationale Catholique des Employés de Commerce, inc.(CSN) », dont la constitution, sous le nom originaire de « Fédération Catholique des Employés du Commerce, de l'Industrie et de la Finance de la Province de Québec inc.», a été autorisée le 16 mai 1945, et dont le siège social est situé à Québec, en celui de « Fédération du Commerce inc.(CSN) », et ce, en vertu de la Loi des syndicats professionnels.Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux, 44185-0 2540-44 Syndicat National des Travailleurs Jcs Pâtes et Papier de Joliette inc.(Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 11 novembre 1971, il a autorisé le changement de nom du « Syndicat National des Travailleurs de la Pulpe et du Papier de Joliette », dont la constitution, sous le nom originaire de « Syndicat Catholique et National des Employés de la Compagnie Barrett », a été autorisée le 21 mars 1941, et dont le siège social est situé à Joliette, en celui de « Syndicat National des Travailleurs des Pâtes et Papier de Joliette inc.», et ce, en vertu de la Loi de; syndicats professionnels, Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44186-0 439-41 Fédération du Commerce inc.(CSN) (Professional Syndicates Ad) Notice is given that on February 2,1971, the Minister of Financial Institutions, Ccmparies and Coopeiatives authorized the change of name of \"Fédération Nationale Catholique des Employés de Commerce, inc.(CSN)\", the incorporation of which, under the origiral name of \"Fédération Catholique des Employes du Commerce, de l'Industrie et de la Finance de la Province de Québec inc.\", was authorized on May 16, 1945, and the head office of which is situated in Québec, into that of \"Fédération du Commerce ire.(CSN)\", and such, pursuant to the Professional Syndicates Act, Revised Statutes.1964, Chapter 146.Roch Rioux, Director of the Companies Service.44185 2540-44 Syndicat National des Travailleurs des Pâtes et Papier de Joliette inc.(Professional Syndicates Act) Notice is given that on November 11, 1971, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives authorized the charge of name of \"Syndicat National des Travailleurs de la Pulpe et du Papier de Joliette\", the incorporation of which, urder the original name of \"Syndicat Catholique et National des Employés de la Compagnie Barrett\", was authorized on March 21, 1941, and the head office of which is situated in Joliette, into that of \"Syndicat National des Travailleurs des Pâtes et Papier de Joliette inc.\", pursuant to the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, chapter 146.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44186 439-41 1080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10f année, n\" A Fédération des Travailleurs du Papier et de la Forêt (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 17 décembre 1971, il a autorisé le changement de nom de « Fédération Canadienne des Travailleurs des Pâtes et Papiers et de la Forêt \u2014 Canadian Federation of Pulp and Paper and Forest Workers\", dont la constitution, sous le nom originaire de « Fédération Nationale Catholique des Employes de Pulperies et Papeteries », a été autorisée le 10 décembre 1937, et dont le siège social est situé à Québec, en celui (le « Fédération des Travailleurs du Papier et de la Forêt », et ce, en vertu de la Loi des syndicats professionnels.Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institut ions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44274-0 3039-37 Fédération des Travailleurs du Papier et de la Forêt (Professional Syndicates Act) Notice is given that, on December 17, 1971, pursuant to the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 146, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives authorized the change of name of the \"Fédération Canadienne des Travailleurs des Pâtes et Papiers et de la Forêt \u2014 Canadian Federation of Pulp and Paper and Forest Workers\", whose incorporation, under the original name of \"Fédération Nationale Catholique des Employés de Pulperies et Papeteries\", was authorized on December 10, 1937, and whose head office is situated in Québec, to that of \"Fédération des Travailleurs du Papier et de la Forêt\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44274 3039-37 Ministère des Affaires municipales Department of Municipal Affairs Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut.Lettres patentes Attendu que chacun des conseils municipaux de la paroisse de Saint-Cécile-du-Bic et du village du Bic, comté de Rimouski a adopté, à la majorité absolue de ses membres, un règlement autorisant la présentation d'une requête conjointe au lieutenant-gouverneur en conseil le priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant ces municipalités et créant une nouvelle municipalité sous l'autorité de la Loi de la fusion volontaire des municipalités; Attendu que les publications requises par l'article 6 de la Loi précitée ont été faites; Attendu Qu'un exemplaire de la requête conjointe a été transmis au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec; Attendu Qu'aucune demande d'enquête n'a été faite à la Commission municipale du Québec et que cette dernière n'a pas tenu une audition publique; Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à la requête conjointe; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 4383, en date du 22 décembre 1971, Nous avons Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.I ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Letters Patent Whereas each of the Municipal Councils of the Parish of St.Cécile-du-Bic and the Village of Bic, County of Rimouski, has passed, by the absolute majority of its members, a by-law authorizing the presentation of a joint petition to the Lieutenant-Governor in Council, praying to be granted letters patent amalgamating these municipalities and creating a new municipality under the Voluntary Amalgamation of Municipalities Act; Whereas the publications prescribed by section 6 of the aforesaid Act have been made; Whereas copies of the joint petition have been transmitted to the Minister of Municipal Affairs and to the Québec Municipal Commission; Whereas no request for an enquiry was made to the Québec Municipal Commission and a public hearing was not held by the said Commission; Whereas it is deemed expedient to comply with the said joint petition; Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 4383, dated December 22.1971.We have decreed and QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.4 1081 décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition de l'honorable ministre des Affaires municipales, que des lettres patentes soient octroyées, fusionnant la paroisse de Sainte-Cécile-du-Bic et le village du Bic, comté de Rimouski, et créant une nouvelle municipalité sous le nom de « Municipalité du Bic », aux conditions mentionnées dans la requête conjointe.Ces conditions sont les suivantes: 1.Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité du Bic » ; 2.Le territoire de la nouvelle municipalité est celui qu'a décrit officiellement le ministère des Terres et Forêts le 22 novembre 1971; cette description apparaît comme annexe A dudit arrêté; 3.La nouvelle municipalité prend le statut de village et est régie par le Code municipal; 4.Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé d'un (1) maire et de six (6) conseillers dont trois (3) de chacune des municipalités requérantes.Le maire sera choisi au scrutin secret, parmi les deux maires en poste, par les deux conseils au complet.Ensuite, chacun des conseils élira trois (3) de ses membres pour faire partie du conseil provisoire.En cas d'égalité, le choix sera fait par tirage au sort par le secrétaire-trésorier; ce conseil sera déterminé lors de la première assemblée du conseil provisoire; 5.La première séance du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura* lieu à 20.00 heures au Centre des Loisirs à Bic; 6.La première élection générale du maire et des conseillers aura lieu le premier dimanche de novembre suivant le trentième jour de l'entrée en vigueur des lettres patentes; la durée du mandat des membres du conseil est de trois (3) ans et, quant au premier mandat, conforme aux dispositions des articles 249c et d du Code municipal; 7.Le siège de chacun des conseillers est numéroté de un (1) à six (6).Le conseil est formé d'un (1) maire et de six (6) conseillers; 8.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des municipalités requérantes, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés, ou abrogés par la nouvelle municipalité; 9.Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des municipalités requérantes, deviendront la propriété de la nouvelle municipalité du Bic; 10.Tous les employés permanents des deux municipalités demeureront à l'emploi de la nouvelle municipalité, au poste qui leur est assigné, à des conditions au moins égales à celles qu'ils détenaient auparavant, et cela jusqu'à décision contraire de la nouvelle municipalité; 11.Le secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité du Bic sera le secrétaire-trésorier de l'ancienne municipalité du village du Bic; 12.Les surplus et déficits accumulés par chacune des municipalités requérantes, seront transportés aux fonds de la nouvelle municipalité; ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Honourable Minister of Municipal Affairs, that letters patent be granted amalgamating the Parish of St.Cécile-du-Bic and the Village of Bic, County of Rimouski, and creating a new municipality under the name of \"Municipality of Bic\", according to the conditions stipulated in the joint petition.These conditions are as follows: 1.The name of the new municipality shall be \"Municipality of Bic\"; 2.The territory of the new municipal^' will be that officially described by the Department of Lands and Forests on November 22,1971; this description appears as Appendix \"A\" of the said Order; 3.The new municipality will have the status of Village and will be governed by the Municipal Code; 4.A provisional council will govern up to the first general election.It will be composed of one (1) mayor and six (6) councillors, three (3) of whom will be from each petitioning municipality.One of the two governing mayors will be elected mayor of the new municipality by both complete councils.Next, each council will elect three (3) of its members to form part of the provisional council.If a decision is not reached, the choice will be made by lot, by the Secretary-Treasurer; this council will be formed at the first sitting of the provisional council; 5.The first sitting of the provisional council will be held the second judicial Monday following the coming into force of the letters patent.It will be held at 8:00 o'clock, p.m., at the Recreational Centre, in Bic; 6.The first general election of a mayor and councillors will be held on the first Sunday of November following the thirtieth day of the coming into force of the letters patent; the term of office of the members of the council will be three (3) years and the first term of office will conform to the provisions of articles 249c and d of the Municipal Code; 7.The seats of the councillors will be numbered from one (1) to six (6).The council will be formed of one (1) mayor and six (6) councillors; 8.The by-laws, resolutions, minutes, valuation rolls, collection rolls and other acts of each of the petitioning municipalities will remain in force in the territory for which they were made until they arc amended, cancelled or repealed by the new municipality; 9.All movable and immovable property belonging to each of the petitioning municipalities will become the property of the new municipality of Bic; 10.All permanent employees of the two municipalities will remain in the employ of the new municipality, in the post assigned them, on conditions at least equal to those which they held formerly, up to a decision to the contrary by the new municipality; 11.The Secretary-Treasurer of the new municipality of Bic will be the Secretary-Treasurer of the former municipality of the Village of Bic; 12.The surpluses and deficits accumulated by each petitioning municipality will be transferred to the funds of the new municipality; 1082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n' 4 13.Pour les cinq (5) premiers exercices financiers de la nouvelle municipalité du Bic, une somme équivalant à un tiers (1/3) des revenus de la compensation de la taxe de vente et appropriée à même cette compensation, sera affectée à de nouveaux développements de la nouvelle municipalité du Bic; 14.Les taxes décrétées aux règlements nos 123 et 130 du village du Bic et no 128 de la paroisse de Sainte-Cécile-du-Bic sont, pour l'avenir, imposées et seront prélevées sur tous les biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité du Bic selon leur valeur, tel qu'il appert du rôle d'évaluation en vigueur chaque année; Les taxes spéciales décrétées aux règlements ncs 88, 114 et 122 du village du Bic, et no 130 de la paroisse de Sainte-Cécile-du-Bie, sont, pour l'avenir, imposées et seront prélevées sur tous les biens-fonds imposables desservis par le réseau d'aqueduc de la nouvelle municipalité du Bic selon leur valeur, tel qu'il appert du rôle d'évaluation en vigueur chaque année; cependant, ces taxes spéciales ne seront prélevées qu'en cas d'insuffisance du tarif de compensation alors en vigueur dans la nouvelle municipalité; 15.La nouvelle municipalité deviendra effective conformément à la loi.Es foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., ch., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-deuxième jour de décembre en l'année mil neuf cent soixante et onze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingtième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Jean Alarie.Libro: 1536 Folio: 14 Avis de l'octroi des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi de la fusion volontaire des municipalités.Le sous-ministre des Affaires municipales, 44249-o Richard Beaulieu.Cité de Kinun Je donne avis qu'à la demande des conseils municipaux de la cité de Rimouski et de la paroisse de Sainte-Anne-dc-la-Pointc-au-Pèrc, j'ai établi, en vertu de l'article 2 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités, chapitre 53 des lois de 1971, une unité de regroupement comprenant la cité de Rimouski.le village de Rimouski-Est et la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père.Cette décision entre eu vigueur le jour de la publication du présent avis.13.For the first five (5) financial years of the new municipality of Bic, a sum equal to one-third (1/3) of the revenue from the sales tax compensation, derived directly from this compensation, will be allocated for new developments in the new municipality of Bic: 14.The taxes decreed in by-laws Nos.123 and 130 of the Village of Bic and No.128 of the Parish of St.Cécile-du-Bic, will be, from now on, imposed and levied on all the taxable immovable property of the new municipality of Bic according to their value, as appears on the valuation roll in force each year; The special taxes decreed in bv-laws Nos.88, 114 and 122 of the Village of Bic, and No.130 of the Parish of St.Cécile-du-Bic, will, from now on, be imposed and levied on all the taxable immovable property served by the aqueduct .system of the new municipality of Bic according to their value, as appears on the valuation roll in force each year; however, these special taxes will be levied only when the compensation tariff then in force in the new municipality will be insufficient: 15.The new municipality will become effective in conformity with the law.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Out Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twenty-second day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and seventy-one and in the twentieth year of Our Reign.By command.Jean Alarie, Assistant Deputy Attorney General.I.ibro: 1536 Folio: 14 Notice of the abovementioned letters patent is given pursuant to the provisions of section 13 of the Voluntary Amalgamation of Municipalities Act.Richard Beaulieu, 44249 Deputy Minister of Municipal Affairs.City of Rimouski Notice is hereby given that at the request of the municipal councils of the City of Rimouski and the Parish of Ste-Anne-de-la-Pointc-au-Pèrc I have established, pursuant to section 2 of Chapter 53 of the Statutes of 1971, an Act to promote the regroup-ment of municipalities, a regroupment unit comprising the City of Rimouski, the Village of Rimouski-Est and the Parish of Ste-Anne-de-la-Pointe-au-Père.This decision shall take effect on the date of tin-publication of this notice.Le ministre des Affaires municipales, Maurice Tessier, q.c., 44249-o Maurice Tessier, c.r.44249-0 Minister of Municipal Affairs. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.k 1083 Avis Le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté le 12e jour de janvier 1972 l'arrêté en conseil No 112-72 qui se lit comme suit: « La ville de Mont Gabriel devient une municipalité constituée en vertu de la Loi de l'organisation municipale de certains territoires (chapitre 54 des lois de 1971) et régie par la Loi des cités et villes.Cet arrêté en conseil entrera en vigueur à compter de la date mentionnée dans l'avis que le ministre donnera dans la Gazette officielle du Québec.» Cette décision prend effet à compter de la date de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Affaires municipales, 44249-0 Maurice Tessier, c.r.Notice The Lieutenant-Governor in Council adopted, on January 12, 1972, Order in Council No.112-72, which reads as follows: \"The town of Mont-Gabriel shall become a municipality constituted pursuant to the Act respecting municipal organization of certain territories (Chapter 54 of the Statutes of 1971) and shall be governed by the Cities and Towns Act.This Order in Council shall come into force upon the date indicated in the notice to be published by the Minister in the Québec Official Gazette.\" This order shall become effective upon the date of publication of this notice in the Québec Official Gazette.44249 Maurice Tessier, q.c.Minister of Municipal Affairs.Soumissions \u2014 Demandes de Tenders \u2014 Requests for Les Commissaires d'écoles pour la municipalité de Saint-Rodrigue Comté de Chauveau Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Paul-Emile St-Onge, secrétaire-trésorier, École Pie XII, 5125, 2ième Avenue Ouest, Charlesbourg, Québec 7, P.Q., jusqu'à 7.30 heures du soir, mercredi, le 16 février 1972, pour l'achat de $344,000 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de Saint-Rodrigue, comté de Chauveau, datées du 1er mars 1972 et remboursables en série du 1er mars 1973 au 1er mars 1992 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-annuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mars 1972.Tableau d'amortissement \u2014 $SLL,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er mars 1973.x $38,000 1er mars 1974.x 41,000 1er mars 1975.x 44,000 1er mars 1976.x 48,000 1er mars 1977.6,000 1er mars 1978 .6,000 1er mars 1979.7,000 1er mars 1980.7,000 1er mars 1981.8,000 1er mars 1982 .8,000 1er mars 1983.9,000 1er mars 1984.10,000 1er mars 1985.11,000 The School Commissioners of the Municipality of St.Rodrigue County of Chauveau Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders tor bonds\" will be received by the undersigned Paul-Émile St-Onge, Secretary-Treasurer, Pie XII School, 5125 2nd Avenue West, Charlesbourg, Québec 7, P.Q., until 7:30 o'clock p.m., on Wednesday, February 16, 1972, for the purchase of a bond issue of $344,000 for the School Commissioners of the Municipality of St.Rodrigue, County of Chauveau, dated March 1, 1972 and redeemable serially from March 1, 1973 to March 1, 1992 inclusive, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable half-yearly on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from March 1, 1972.Redemption table \u2014 $Sil,,000 \u2014 20 years Year Capital March 1, 1973.x $38,000 March 1,1974.x 41,000 March 1, 1975.x 44,000 March 1, 1976.x 48,000 March 1, 1977 .6,000 March 1, 1978.6,000 March 1,1979 .7,000 March 1, 1980.7,000 March 1, 1981.8,000 March 1,1982 .8,000 March 1, 1983.9,000 March 1, 1984.10,000 March 1, 1985.11,000 1084 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i' année, n° k 1er mars 1986.S 12,000 1er mars 1987.12,000 1er mars 1988.13,000 1er mars 1989.14,000 1er mars 1990.15,000 1er mars 1991.17,000 1er mars 1992.18,000 Les « x » indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'une subvention de $184,000, accordée par le gouvernement provincial et payable en 4 versements de $46,000 de 1973 à 1976 inclusivement, seront appliqués au service de cet emprunt.Les versements effectués à même cette subvention seront déposés durant les années précitées entre les mains du ministre des Finances en vue de compléter les sommes nécessaires pour acquitter en totalité le service de la dette sur cette émission conformément aux dispositions du Bill 64.Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Saint-Rodrigue, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demanderont au ministre de l'Education d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire (y compris celles indiquées ci-haut), le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des Finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $18,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er mars 1992.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Charlesbourg.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.March 1, 1986.$ 12,000 March 1, 1987.12.000 March 1, 1988.13,000 March 1, 1989.14,000 March 1, 1990.15,000 March 1, 1991.17,000 March 1, 1992.18,000 The years marked with the letter \"x\" indicate those years during which the annual instalments of a grant of S184.000, awarded by the Provincial Government and payable in 4 instalments of $46,000 from 1973 to 1976 inclusive, will be applied to the service of this loan.The instalments paid on such grant will be deposited during the aforesaid years with the Minister of Finance for the purpose of completing the sums required to pay off the aggregate amount of the debt service on this issue, in conformity with the provisions of Bill 64.The School Commissioners of the Municipality of St.Rodrigue, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Boards Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by the Minister of Education to the said school corporation (including those indicated above), the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds will not be for an amount less than $18,000, and if greater than the latter amount, the said surplus must only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of March 1, 1992.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at Charlesbourg.Capital and interest are payable at all branches in the Provmce of Québec of the bank mentioned in the loan procedure. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.m.No.L 1085 Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 818,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 1er mars de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Saint-Rodrigue s'engagent à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er mars 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu de la résolution datée du 7 juillet 1971 \u2014 $344,000 \u2014 agrandissement de deux (2) écoles.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue à,7.30 heures du soir, mercredi, le 16 février 1972, École Pie XII, 5125, 2ième Avenue Ouest, Charlesbourg, Québec 7, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Charlesbourg, ce 20 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, Paul-Émile St-Onge.École Pie XII, 5125, 2ième Avenue Ouest, Charlesbourg, Québec 7, P.Q., Téléphone : 626-8222, code 418.44276-0 Ville de Bagotville Comté de Chicoutimi Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné J.Eugène Tremblay, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville.Salle de délibération du conseil, 200, rue Victoria, Bagotville, comté de Chicoutimi, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, lundi, le 14 février 1972, pour l'achat de $291,000 d'obligations de la ville de Bagotville, comté de Chicoutimi, datées du 1er mars 1972 et remboursables en série du 1er mars 1973 au 1er mars 1992 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-annuelle-ment les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mars 1972.Tableau d'amortissement \u2014 S291,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er mars 1973.$12,500 1er mars 1974.13,500 1er mars 1975.14,500 1er mars 1976.15,500 The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $18,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on March 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The School Commissioners of the Municipality of St.Rodrigue agree not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after March 1, 1972, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the resolution dated July 7, 1971 \u2014 $344,000 \u2014 enlargement of two (2) schools.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held at 7:30 o'clock p.m., on Wednesday, February 16, 1972, at Pie XII School, 5125, 2nd Avenue West, Charlesbourg, Québec 7, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Charlesbourg, January 20, 1972.Paul-Émile St.-Onge, Secretary-Treasurer.Pie XII School, 5125, 2nd Avenue West, Charlesbourg, Québec 7, P.Q., Telephone: 626-8222, code 418.44276 Town of BagotviUe County of Chicoutimi Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" be received by the undersigned, J.-Eugène Tremblay, Secretary-Treasurer, in the Town Hall, Council Meeting Room, 200 Victoria Street, Bagotville, County of Chicoutimi, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Monday, February 14, 1972, for the purchase of a bond issue of $291,000 for the Town of Bagotville, county of Chicoutimi, dated March 1, 1972, and redeemable serially from March 1, 1973 to March 1, 1992 inclusive, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable half-yearly on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from March 1, 1972.Redemption table \u2014 $291,000 \u2014 20 years Year Capital March 1, 1973.$12,500 March 1, 1974.13,500 March 1, 1975.14,500 March 1, 1976.15,500 1086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i' année, «\u2022 i 1er mars 1977.$16,500 1er mars 1978.8,500 1er mars 1979 .8,500 1er mars 1980 .9,500 1er mars 1981.10,000 1er mars 1982.11,000 1er mars 1983.12,000 1er mars 1984.13,000 1er mars 1985.14,000 1er mars 1986.15,000 1er mars 1987.16,000 1er mars 1988.17,500 1er mars 1989.18,500 1er mars 1990 .20,000 1er mars 1991.22,000 1er mars 1992 .23,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $23,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er mars 1992.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Bagotville.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetablcs par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $23,000 et seul cet excédent sera rachctable par anticipation, au pair, le 1er mars de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Bagotville s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er mars 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.March 1, 1977.$16,500 March 1, 1978 .8,500 March 1, 1979 .8,500 March 1, 1980.9,500 March 1.1981.10,000 March 1, 1982.11,000 March 1, 1983.12,000 March 1, 1984.13,000 March 1, 1985.14,000 March 1, 1986.15,000 March 1, 1987.16,000 March 1, 1988.17,500 March 1, 1989.18,500 March 1, 1990 .20,000 March 1,1991.22.000 March 1, 1992 .23,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-terra bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $23,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the tables of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of March 1, 1992.However, tenders should be sent for only one of the above methc/ds of issue, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at Bagotville.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $23,000.and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par.on March 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the'loan.The town of Bagotville agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after March 1, 1972 without written authorization from the successful tenderer of the present issue. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1087 Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 339 \u2014 $41,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 441-71 \u2014 $250,000 \u2014aqueduc, égouts, voirie, éclairage, etc.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue, lundi, le 14 février 1972, à 8 heures du soir.Hôtel de ville, Salle de délibération du conseil, 200, rue Victoria, Bagotville, cemté de Chicoutimi, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Bagotville (Comté de Chicoutimi), ce 17 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, J.-Eugène Tremblay.Hôtel de ville.Salle de deliberation du conseil, 200, rue Victoria, Bagotville (Chicoutimi), P.Q.Téléphone: 544-1614, code 418.44183-o Les Commissaires d'écoles pour la municipalité de Port-Cartier Comté de Saguenay Avis public est par les présentes donné que des soumissiors cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Bernard Otis, secrétaire-trésorier, Bureau administratif de la commission scolaire, case postale 550, Port-Cartier, comté de Saguenay, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 15 février 1972, pour l'achat de $439,000 d'obligations pour les commissaires d'écoles pour la municipalité de Port-Cartier, comté de Saguenay, datées du 1er mars 1972 et remboursables en série du 1er mars 1973 au 1er mars 1982 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-annuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mars 1972.Tableau d'amortissement \u2014 $439,000 \u2014 10 ans Année Capital * 1er mars 1973.$34,500 1er mars 1974.35,500 1er mars 1975.37,500 1er mars 1976.39,500 1er mars 1977 .42.500 1er mars 1978 .44,500 1er mars 1979.47,500 1er mars 1980 .49,500 1er mars 1981.52,500 1er mars 1982.55,500 Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Port-Cartier, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 339 \u2014 841,000 \u2014 loan renewal; 441-71 \u2014 $250,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads, lighting, etc.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held on Monday, February 14, 1972, at 8:00 o'clock p.m., in the Town Hall, Council Meeting Room, 200 Victoria Street, Bagotville, county of Chicoutimi, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Bagotville (Countv of Chicoutimi), January 17.1972.J.-Eugène Tremblay, Secretary-Treasurer.Town Hall, Council Meeting Room, 200 Victoria Street, Bagotville, (Chicoutimi), P.Q.Telephone: 544-1614, code 418.44183 The School Commissioners of the Municipality of Port-Cartier County of Saguenay Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Bernard Otis, Secretary-Treasurer, at the School Commission Administration Office, Post Office Box 550, Port-Cartier, County of Saguenay, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, February 15, 1972, for the purchase of a bond issue of $439,000 for the School Commissioners of the Municipality of Port-Cartier, County of Saguenay, dated March 1, 1972 and redeemable serially from March 1, 1973 to March 1, 1982 inclusive, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable half-yearly on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown on the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from March 1, 1972.Redemption table \u2014 $439,000 \u2014 10 years Year Capital March 1, 1973.$34,500 March 1, 1974 .35,500 March 1, 1975.37,500 March 1, 1976 .39,500 March 1, 1977 .42,500 March 1, 1978 .44,500 March 1, 1979.47,500 March 1, 1980 .49,500 March 1, 1981.52,500 March 1, 1982.55,500 The School Commissioners of the Municipality of Port-Cartier, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Boards Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64).will request the 1088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10A' année, n° A demanderont au ministre de l'Éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicom-mis, entre les mairs du ministre des Firances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.On est prié de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix irdiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Port-Cartier.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Port-Cartier s'engagent à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er mars 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présenteémis-ion.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 26 mai 1961 \u2014 S414.0C0 \u2014 renouvellement d'emprunt; 8 novembre 1971 \u2014 $25,000 \u2014 frais de refinancement.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue, mardi, le 15 février 1972, à 8 heures du soir, Bureau admii istratif de la commission scolaire, case postale 550, Port-Cartier, comté de Sagueray, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Port-Cartier (Comté de Saguenay), ce 19 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, Bernard Otis.Bureau administratif de la commission scolaire, Case postale 550, Port-Cartier (Comté de Saguenay), P.Q.Téléphone : 766-2912, code 418.44237-0 Ville de Cowansville Comté de Missisquoi Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Georges Bernier, greffier.Hôtel de ville, 220, Place municipale, Cowansville, comté de Missisquoi, P.Q., jusqu'à 5 heures de l'après-midi, lundi, le 14 février 1972, pour l'achat de $430,000 d'obligations de la ville de Cowansville, comté de Missisquoi, datées du 1er mars 1972 et remboursables en série du 1er mars 1973 au 1er mars 1992 inclusivement, avec intérêt à Minister of Education to deposit in trust with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by the Minister of Education to the said corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Please note that tenders are called for bonds redeemable according to the above table only, and that offers for short-term bonds will not be considered.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at Port-Cartier.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The School Commissioners of the Municipality of Port-Cartier agree not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after March 1, 1972 without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: May 26, 1961 \u2014 $414,000 \u2014 loan renewal; November 8, 1971 \u2014 $25,000 \u2014 financing costs.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Tuesday, February 15, 1972, at 8:00 o'clock p.m., at the School Commission Administration Office, Post Office Box 550, Port-Cartier, County of Saguenay, P.Q.The School commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Port-Cartier (County of Saguenay), January 19, 1972.Bernard Otis, Secretary-Treasurer.School Commission Administration Office, Post Office Box 550, Port-Cartier (County of Saguenay), P.Q.Telephone: 766-2912, code 418.44237 Town of Cowansville County of Missisquoi Public notice is hereby given that scaled tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Georges Bernier, Town Clerk, at the Town Hall, 220 Place Municipale, Cowansville, County of Missisquoi, P.Q., until 5:00 o'clock, p.m., on Monday, February 14, 1972, for the purchase of a bond issue of $430,000 for the Town of Cowansville, County of Missisquoi, dated March 1, 1972 and redeemable serially from March 1, 1973 to March 1, 1992 inclusive, with interest at a rate of not less than 'QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.4 10S9 un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-annuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mars 1972.Tableau d'amortissement \u2014 $430,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er mars 1973.$10,500 1er mars 1974.11,500 1er mars 1975.11,500 1er mars 1976.13.000 1er mars 1977.13,500 1er mars 1978.14,500 1er mars 1979.16,000 1er mars 1980.16,500 1er mars 1981.17,000 1er mars 1982.19,500 1er mars 1983 .20,000 1er mars 1984.22,000 1er mars 1985.23,000 1er mars 1986.25,000 1er mars 1987 .27,000 1er mars 1988.29,000 1er mars 1989 .31,500 1er mars 1990.32,500 1er mars 1991.35,000 1er mars 1992 .41,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $41,500 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er mars 1992.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Cowansville.7%, nor more than 8%, payable half-yearly on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from March 1, 1972.Redemption table \u2014 $430,000 \u2014 20 years Year Capital March 1, 1973.$10,500 March 1,1974.11,500 March 1, 1975.11,500 March 1,1976.13,000 March 1, 1977.13,500 March 1, 1978.14,500 March 1, 1979.16,000 March 1, 1980.16,500 March 1, 1981.17,000 March 1, 1982.19,500 March 1, 1983 .20,000 March 1, 1984 .22,000 March 1, 1985.23,000 March 1, 1986.25,000 March 1, 1987.27,000 March 1, 1988.29,000 March 1, 1989.31,500 March 1, 1990.32,500 March 1, 1991.35,000 March 1, 1992 .41,500 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $41,500 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of March 1, 1992.However, tenders should be sent for one only of the above methods of issue, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.i The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at Cowansville. 1090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1912', 104' année, n° i Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachctables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $41,500 et seul cet excédent sera rachetaole par anticipation, au pair, le 1er mars de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à \\% du montant de l'emprunt.La ville de Cowansville s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er mars 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 495 \u2014 $44,000 \u2014 aqueduc, égouts; 497 \u2014 $200,000 \u2014 construction d'une usine de pompage; 621 \u2014 $65,000 \u2014 refinancement; 623 \u2014 $43,000 aqueduc, égouts; 630 \u2014 $13,000 \u2014 aqueduc, égouts; 635 \u2014 $65,000 \u2014 projet municipal d'habitation.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue, lundi, le 14 février 1972, à 5 heures de l'après-midi, Hôtel de ville, 220, Place municipale, Cowansville, comté de Missisquoi, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Cowansville (Comté de Missisquoi), ce 18 janvier 1972.Le greffier, Georges Bernier.Hôtel de ville, 220, Place municipale, Cowansville (Comté de Missisquoi), P.Q.Téléphone: 263-0141, code 514.44184-o Les Commissaires d'écoles pour la municipalité de Pont-Viau Comté de Fabre Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Maurice Pépin, secrétaire-trésorier, Bureau de la commission, 70, rue Lahaie, district de Pont-Viau, Laval, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 15 février 1972, pour l'achat de $107,500 d'obligations pour les commissaires d'écoles pour la municipalité de Pont-Viau, comté de Fabre, datées du 1er mars 1972 et remboursables en série du 1er mars 1973 au 1er mars 1982 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-annuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $41,500, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on March 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Cowansville agrees not to bring out new bonds on the Canadian market within the sixty days upon, from and after March 1, 1972, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 495 \u2014 $44,000 \u2014 aqueduct, sewers; 497 \u2014 $200,000 \u2014 construction of a pumping plant; 621 \u2014 $65,000 \u2014 refinancing; 623 \u2014 $43,000 \u2014 aqueduct, sewers; 630 \u2014 $13,000 \u2014 aqueduct, sewers; 635 \u2014 $65,000 \u2014 municipal housing plans.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the council or of one of its committees, as the ease may be, to be held on Monday, February 14, 1972, at 5:00 o'clock, p.m., at the Town Hall, 220 Place Municipale, Cowansville, County of Missisquoi, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Cowansville (County of Missisquoi), January 18, 1972.Georges Bernier, Town Clerk.Town Hall, 220 Place Municipale, Cowansville (County of Missisquoi), I'.Q.Telephone: 263-0141, code 514.44184 The School Commissioners of the Municipality of Pont-Viau County of Fabre Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Maurice Pépin, Secretary-Treasurer, at the School Commission Office, 70 Lahaie Street, District of Pont-Viau, Laval, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, February 15, 1972, for the purchase of a bond issue of $107,500 for the School Commissioners of the Municipality of Pont-Viau, County of Fabre, dated March 1, 1972 and redeemable serially from March 1, 1973, to March 1, 1982 inclusive, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable half-yearly on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1091 taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mars 1972.Tableau d'amortissement \u2014 $107,500 \u2014 10 ans Année Capital 1er mars 1973.S 8,000 1er mars 1974 .8,500 1er mars 1975 .9,000 1er mars 1976 .9,500 1er mars 1977.10,500 1er mars 1978.11,000 1er mars 1979.11,500 1er mars 1980.12,000 1er mars 1981.13,500 1er mars 1982.14,000 Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Pont-Viau, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires Chapitre 63 des Lois de 196S) (Bill 64) demanderont au ministre de l'Education d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.On est prié de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Laval.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas raehetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Pont-Viau s'engagent à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er mars 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 14 novembre 1961 \u2014 8101,500 \u2014 renouvellement d'emprunt: 9 novembre 1971 \u2014 $6,000 \u2014 frais de refinancement.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue, mardi, le 15 février 1972, à 8 heures du soir.Bureau de la commission, 70, rue Lahaie, district de Pont-Viau, Laval, P.Q.must cover one or several complete annual redemptions, as shown on the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from March 1, 1972.Redemption table \u2014 $107,500 \u2014 10 years Year Capital March 1, 1973.$ 8,000 March 1, 1974 .8,500 March 1, 1975 .9,000 March 1,1976 .9,500 March 1,1977.10,500 March 1, 1978.11,000 March 1, 1979.11,500 March 1, 1980.12,000 March 1, 1981.13,500 March 1, 1982.14,000 The School Commissioners of the Municipality of Pont-Viau, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Boards Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64).will request the Minister of Education to deposit in trust with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by the Minister of Education to the said corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Please note that tenders are called for bonds redeemable according to the above table only, and that offers for short-term bonds will not be considered.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at Laval.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The School Commissioners of the Municipality of Pont-Viau agree not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after March 1, 1972, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: November 14, 1961 \u2014 $101,500 \u2014 loan renewal; November 9,1971 \u2014 $6,000 \u2014 financing costs.Tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Tuesday, February 15, 1972, at 8:00 o'clock p.m., at the School Commission Office, 70 Lahaie Street, District of Pont-Viau, Laval, P.Q. 1092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S9 janvier 197S, 10b' année, n° b Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Pont-Viau (Comté de Fabre), ce 18 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, Maurice Pépin.Bureau de la commission, 70, rue Lahaie, District de Pont-Viau, Laval, P.Q.Téléphone: 663-3931, code 514.44238-0 Ville de Saint-Huliert Comté de Taillon Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Yvon Grenier, greffier, jusqu'à 5 heures de l'après-midi.Hôtel de Ville, 7500, Chemin Chambly, St-Hubert, comté de Taillon, l'.Q., et par après jusqu'à 8 heures du soir, Salle des Assemblées du Conseil, 3350, Grande-Allée, St-Hubert, comté de Taillon.P.Q., lundi, le 14 février 1972, pour l'achat de $1,890,000 d'obligations de la ville de St-Hubert, comté de Taillon, datées du 1er mars 1972 et remboursables en série du 1er mars 1973 au 1er mars 1992 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%.payable semi-annuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mars 1972.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Pont-Viau (County of Fabre), January IS, 1972.Maurice Pépin, Secretary-Treasurer.School Commission Office, 70 Lahaic Street, District of Pont-Viau, Laval, P.Q., Telephone: 663-3931, code 514.4423S Town of St.Hubert County of Taillon Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Yvon Grenier, Town Clerk, until 5:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 7500 Chambly Road, St.Hubert, County of Taillon, P.Q., and thereafter imtil 8:00 o'clock p.m., in the Council Meeting Room, 3350 Grande Allée, St.Hubert, County of Taillon, P.Q., on Monday, February 14, 1972, for the purchase of a bond issue of S1.890,0t0 for the Town of St.Hubert, County of Taillon, dated March 1, 1972 and redeemable serially from March 1, 1973 to March 1, 1992 inclusive, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable half-yearly on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption tables in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from March 1, 1972.Tableau d'amortissement \u2014 tl,890,000 \u2014 SO ans Année Capital 1er mars 1973.S 56,000 1er mars 1974 .59,000 1er mars 1975 .63,000 1er mars 1976 .69,000 1er mars 1977.75,000 1er mars 1978 .81,000 1er mars 1979 .86,000 1er mars 1980.90,000 1er mars 1981.91,000 1er mars 1982 .96.000 1er mars 1983.48.000 1er mars 1984 .52.000 1er mars 1985 .56.000 1er mars 1986 .60.000 1er mars 1987 .65,000 1er mars 1988 .71,000 1er mars 1989.75,000 1er mars 1990.82,000 1er mars 1991.87,000 1er mars 1992 .528,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.Rédemption table \u2014 $1,890,000 \u2014 SO years Year Capital March 1, 1973.$ 56,000 March 1, 1974 .59,000 March 1, 1975 .63,000 March 1, 1976.69,000 March 1, 1977 .75,000 March 1, 1978 .81.000 March 1, 1979 .86,000 March 1, 1980.90.000 March 1, 1981.91,000 March 1, 1982.96,000 March 1.1983 .48,000 March 1, 1984.52.000 March 1, 1985.56,000 March 1, 1986.60,000 March 1, 1987 .65,000 March 1, 1988 .71 000 March 1, 1989.75 000 March 1, 1990 .82'000 £!arch J.'99'.8/000 March 1, 1992.528,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.I 1.093 2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans ave le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $60,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er mars 2002 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er mars 1992 au montant de 8528,000 comprend un solde de $433,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: Année Capital 1er mars 1993.$29,000 1er mars 1994.32,000 1er mars 1995.34,000 1er mars 1996.38,000 1er mars 1997.40,000 1er mars 1998.44,000 1er mars 1999.48,000 1er mars 2000.52,000 1er mars 2001.56,000 1er mars 2002 .60,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Hubert.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $528,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er mars de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de St-Hubert s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er mars 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 84 \u2014 $58,000 \u2014 renouvellement d'em- 2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $60,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of March 1, 2002 of the renewable part hereinafter mentioned.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of March 1, 1992 in the amount of $528.000 includes a balance of 8433,000 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Year Capital March 1, 1993.$29,000 March 1, 1994.32,000 March 1, 1995.34,000 March 1, 1996.38,000 March 1,1997.40,000 March 1, 1998.44,000 March 1, 1999.48,000 March 1,2000.52,000 March 1,2001.56,000 March 1, 2002.60,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, including capital and any interest, by certified cheque payable at par at St.Hubert.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the bead office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $528.000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on March 1st of each year for the annual amotnt required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of St.Hubert agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market upon, from and after March 1, 1972, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 84 \u2014 $58,000 \u2014 loan renewal; 85 \u2014 109-1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10k' année, n° k prurit; 85 \u2014 $32,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 96 \u2014 $373,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 97 \u2014 $40,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 177 \u2014 $101,500 \u2014 voirie; 348 \u2014 $100,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 349 \u2014 $500,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 350 \u2014 $300,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 351 \u2014 $300,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie ; 382 \u2014 $85.500 \u2014 aqueduc, égouts et voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées ù une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8 heures du soir, lundi, le 14 février 1972, à la Salle des Assemblées du Conseil, 3350, Grande-Allée, St-Hubert, comté de Taillon, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Hubert (Comté de Taillon), ce 19 janvier 1972.Le greffier, Yvon Grenier.Hôtel de Ville, 7500, Chemin Chambly, St-Hubert (Taillon), P.Q.Téléphone: 676-7744, code 514.44275-0 Cité de Shawinigan Comté de Saint-Maurice Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Yvon Boisvert, greffier, Hôtel de Ville, rue des Cèdres, Shawinigan, comté de Saint-Maurice, P.Q., jusqu'à 2 heures de l'après-midi, mardi, le 15 février 1972, pour l'achat de $1,500,000 d'obligations de la cité de Shawinigan, comté de Saint-Maurice, datées du 1er mars 1972 et remboursables en série du 1er mars 1973 au 1er mars 1992 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-annuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mars 1972.Tableau d'amortissement \u2014 SI,500,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er mars 1973.$ 61,000 1er mars 1974 .66,000 1er mars 1975 .69,000 1er mars 1976 .74,000 1er mars 1977 .81,000 1er mars 1978 .88,000 1er mars 1979 .93,000 1er mars 1980.100,000 1er mars 1981.107.000 1er mars 1982.114,000 1er mars 1983.46,000 1er mars 1984.50.000 1er mars 1985 .54,000 1er mars 1986 .59,000 $32,000 \u2014 loan renewal; 96 \u2014 $373,000 \u2014 loan renewal; 97 \u2014 $40,000 \u2014 loan renewal; 177 \u2014 $101,500 \u2014 roads; 348 \u2014 $100,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 349 \u2014 $500,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 350 \u2014 $300,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads ; 351 \u2014 $300,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 382 \u2014 $85,500 \u2014 aqueduct, sewers and roads.¦ Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held at 8:00 o'clock p.m., on Monday, February 14, 1972, in the Council Meeting Room,'3350 Grande Allée, St.Hubert, County of Taillon, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St.Hubert (County of Taillon), January 19, 1972.Yvon Grenier, Town Clerk.Town Hall, 7500 Chambly Road, St.Hubert (Taillon), P.Q.Telephone : 676-7744, code 514.44275 City of Shawinigan County of Saint-Maurice Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Yvon Boisvert, City Clerk, at the City Hall, des Cèdres Street, Shawinigan, County of Saint-Maurice, P.Q., until 2:00 o'clock p.m., on Tuesday, February 15, 1972, for the purchase of a bond issue of $1,500,000 for the City of Shawinigan, County of Saint-Maurice, dated March 1st 1972 and redeemable serially from March 1st 1973 to March 1st 1992 inclusive, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable half-yearly on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from March 1st 1972.Redemption table \u2014 $1,500,000 \u2014 20 years Year Capital March 1, 1973.$ 61,000 March 1, 1974 .66,000 March 1, 1975 .69,000 March 1, 1976 .74,000 March 1, 1977 .81,000 March 1, 1978.88,000 March 1, 1979.93,000 March 1, 1980.100,000 March 1, 1981.107,000 March 1, 1982.114,000 March 1, 1983.46,000 March 1, 1984 .50,000 March 1, 1985 .54,000 March 1, 1986.59,000 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10b, No.b 1095 1er mars 1987.863,000 1er mars 1988.68,000 1er mars 1989.73,000 1er mars 1990 .78,000 1er mars 1991.78,000 1er mars 1992 .78,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant eu série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans^ Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 878,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er mars 1992.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Shawinigan.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau prmcipal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $78,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er mars de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La cité de Shawinigan s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er mars 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 940 \u2014 $322,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 1358 \u2014 $120,000 \u2014 acquisition de terrains et bâtisses; 1370 (tel que modifié) \u2014 885,000 \u2014 égouts; 1376 \u2014 8955,000 \u2014 pavage; 1394 \u2014 $18,000 \u2014 frais de refinancement.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités.March 1, 1987.$63,000 March 1, 1988.68,000 March 1, 1989 .73,000 March 1, 1990.78,000 .March 1, 1991.78,000 March 1, 1992.78,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $78,000 and if greater than the latter amount, the said surplus must only comprise one or several complete annual redemption taking into account the tables of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of March 1st 1992.However, tenders should be sent for one only of the above methods of issue and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at Shawinigan.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $78,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on March 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of Shawinigan agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after March 1st 1972, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 940 \u2014 $322,000 \u2014 loan renewal; 1358 \u2014 $120,000 \u2014 purchase of land and buildings; 1370 (as amended) \u2014 $85,000 \u2014 sewers; 1376 \u2014 $955,000 \u2014 paving; 1394 \u2014 $18,000 \u2014 refinancing costs.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the council or of one of its committees. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101* année, n° 4 1096 selon le cas, qui sera tenue mardi, le 15 février 1972, à 2 heures de l'après-midi.Hôtel de Ville, Rue des Cèdres, Shawinigan, comté de Saint-Maurice, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Shawinigan (Comté de Saint-Maurice), ce 18 janvier 1972.Le greffier, Yvon Boisvert.Hôtel de Ville, rue des Cèdres, Shawinigan, (Saint-Maurice), P.Q., Téléphone: 537-1003, code 819.44239-0 Ville de Douvillc Comté de Saint-Hyacinthe Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Jacques Archambault, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, 610, rue Chapleau, Douville, comté de Saint-Hyacinthe, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mercredi, le 16 février 1972, pour l'achat de $256,000 d'obligations de la ville de Douville, comté de Saint-Hyacinthe, datées du 1er mars 1972 et remboursables en série du 1er mars 1973 au 1er mars 1992 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieure à 8%, payable semi-annuallement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mars 1972.Tableau d'amortissement \u2014 $266,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er mars 1973.$ 3,000 1er mars 1974.3,000 1er mars 1975 .3,500 1er mars 1976 .3,500 1er mars 1977 .4,000 1er mars 1978.4,000 1er mars 1979.4,500 1er mars 1980.4,500 1er mars 1981.5,000 1er mars 1982.5,500 1er mars 1983 .5,500 1er mars 1984.5,500 1er mars 1985.6,000 1er mars 1986 .6,500 1er mars 1987.7,000 1er mars 1988 .7,500 1er mars 1989 .8,500 1er mars 1990.9,000 1er mars 1991.9,500 1er mars 1992.150,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: as the case may be, to be held on Tuesday, February 15, 1972, at 2:00 o'clock p.m., at the City Hall, des Cèdres Street, Shawinigan, County of Saint-Maurice, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Shawinigan (County of Saint-Maurice), January 18, 1972.Yvon Boisvert, City Clerk, City Hall, des Cèdres Street, Shawinigan, (Saint-Maurice), P.Q., Telephone: 537-1003, code 819.44239 Town of Douville County of St.Hyacinthe Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Jacques Archambault, Secretary-Treasurer, at the Town Hall.610 Chapleau Street, Douville, County of St.Hyacinthe, P.Q., until 8:00 o'clock, p.m., on Wednesday, February 16, 1972, for the purchase of a bond issue of $256,000 for the Town of Douville, County of St.Hyacinthe, dated March 1, 1972 and redeemable serially from March 1, 1973 to March 1, 1992 inclusive, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable half-yearly on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than ore rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption tables in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from March 1, 1972.Redemption table \u2014 $266,000 \u2014 20 years Year Capital March 1, 1973.$ 3,000 March 1, 1974 .3\\000 March 1, 1975 .3,500 March 1,1976.3,500 March 1,1977 .4,000 March 1, 1978 .4,000 March 1,1979 .4,500 March 1, 1980.4,500 March 1, 1981.5 000 March 1, 1982.5 500 March 1, 1983.5,500 March 1, 1984.:.5,500 March 1, 1985.6,000 March 1, 1986.6^500 March 1, 1987 .7 000 March 1, 1988.7',500 March 1, 1989 .8 500 March 1, 1990.g'ooo March 1,1991.9^500 March ,,1992.150^500 Moreover, the following terms and conditions only will be considered : 1 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1097 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 uns avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 uns avec le solde reporté à 10 uns pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 818,500, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le préseul avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er mars 2002 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des ternies sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er mars 1992 au montant de $150,500 comprend un solde de 8140,500 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans et échéant comme suit: /Innée Capital lermars 1993.$10.500 1er mars 1994.11.500 1er mars 1995.12.000 1er mars 1996.12.500 1er mars 1997.13,500 1er mars 1998.14,000 1er mars 1999.15,000 1er mars 2000.16.000 1er mars 2001.17,000 1er mars 2002.18,500 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Hyacinthe.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetablcs par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $150,500, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er mars de chaque année pour le montant annuel requis |>our les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Douville s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er mars 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to teji years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $18,500, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of March 1, 2002 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of March 1, 1992 in the amount of $150.500 includes a balance of $140,500 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Year Capital March 1, 1993.$10.500 March 1, 1994.11,500 March 1, 1995.12,000 March 1, 1996.12,500 March 1, 1997.13,500 March 1, 1998.14,000 March 1, 1999.15,000 March 1,2000.16,000 March 1, 2001.17,000 March 1, 2002.18,500 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at St.Hyacinthe.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $150,500 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on March 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notieç.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Douville agrees not to bring out new bonds on the Canadian market within the sixty days upon, from and after March 1, 1972, without written authorization from the successful tenderer of the present issue. 109S GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 101- année, n' 4 Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 36 \u2014 $247,500 \u2014 renouvellement d'emprunt: 144 \u2014 $8,500 \u2014 frais de refinancement.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8 heures du soir, mercredi, le 16 février 1972, Hôtel de Ville, 610.rue Chapleau, Douville, comté de Saint-Hyacinthe, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Douville (Comté de Saint-Hyacinthe), ce 18 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, Jacques Archambault.Hôtel de Ville.610.rue Chapleau, Douville (Saint-Hyacinthe), P.Q.Téléphone: 774-4655, code 514.44236-0 Les Commissaire d'écoles pour la municipalité de la ville de Ste-Thérèse Comté de Terrebonne Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscripticn « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Raymond Thibault, secrétaire-trésorier.Pavillon J.L.Blanchard, 6, rue Tassé, cité de Ste-Thérèse, comté de Terrebonne, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, jeudi, le 17 février 1972, pour l'achat de SI 56,500 d'obligations pour les commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de Sainte-Thérèse, comté de Terre-bonne, datées du 1er mars 1972 et remboursables en série du 1er mars 1973 au 1er mars 1982 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7% ni supérieur à 8% payable semi-annucllcment les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mars 1972.Tableau d'amortissement \u2014 $166,600 \u2014 10 ans Année Capital 1er mars 1973.$11,500 1er mars 1974.12,500 1er mars 1975.13,500 1er mars 1976.14,000 1er mars 1977.15,000 1er mars 1978.16,000 1er mars 1979.17,000 1er mars 1980.18,000 1er mars 1981.19,000 1er mars 1982.20,000 Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de Sainte-Thérèse, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demanderont au ministre de l'Éducation d'effectuer The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 36 \u2014 $247,500 \u2014 loan renewal; 144 \u2014 $8,500 \u2014 refinancing costs.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the council or of one of its committees, as the case may be, to be held at 8:00 o'clock, p.m.on Wednesday, February 16, 1972, at the Town Hall, 610 Chapleau Street, Douville, County of St.Hyacinthe, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Douville (County of St.Hyacinthe), January 18, 1972.Jacques Archambault, Secretary-Treasurer.Town Hall.610 Chapleau Street, Douville (St.Hvacinthe), P.Q.Telephone: 774-4655, code 514.44236 The School Commissioners for the Municipality of the City of Ste.Thérèse County of Terrebonne Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Raymond Thibault, Secretary-Treasurer at the J.L.Blanchard Pavillon, 6 Tassé Street, City of Ste.Thérèse, County of Terrebonne, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Thursday, February 17, 1972, for the purchase of a bond issue of 8156,500 for the School Commissioners for the Municipality of the City of Ste.Thérèse, County of Terrebonne, dated March 1, 1972 and redeemable serially Irom March 1, 1973 to March 1, 1982 inclusive, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable half-yearly on March 1 and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from March 1, 1972.Redemption table \u2014 $156,600 \u2014 10 years Year Capital March 1, 1973.$11,500 March 1, 1974.12,500 March 1, 1975.13,500 March 1, 1976.14,000 March 1, 1977.15,000 March 1, 1978.16,000 March 1, 1979.17,000 March 1, 1980.18,000 March 1, 1981.19 000 March 1, 1982 .2o!oOO The School Commissioners tor the Municipality of the City of Ste.Thérèse, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Boards Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister 01 Education to deposit iu trust QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.k 1099 à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéi-commis, entre les mains du ministre des Finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.On est prié de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Ste-Thérèse.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachctables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de Sainte-Thérèse s'engagent à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er mars 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 27 octobre 1961 \u2014 $147.500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 23 novembre 1971 \u2014 $9,000 \u2014 frais de refinancement.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue, jeudi, le 17 février 1972, à S heures du soir, Pavillcn J.L.Blanchard, 6, rue Tassé, cité de Ste-Thérèse, comté de Terrebonne, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ste-Thérèse (Comté de Terrebonne), ce 19 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, Raymond Thibault.Pavillon J.L.Blanchard, 6, rue Tassé, Cité de Ste-Thérèse (Terrebonne), P.Q.Téléphone: 430-2200, code 514.44318-0 Ville de Pointe-Catineau Comté de Hull Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Louis Lamarche, greffier, Hôtel de ville, 17, nie Jacques-Cartier, Pointe-Gatincau, comté de Hull, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, jeudi, le 17 février 1972, pour l'achat de $1,530,500 d'obligations de la ville de Pointe-Gati-neau, comté de Hull, datées du 1er mars 1972 et remboursables en série du 1er septembre 1973 au 1er sep- with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by the Minister of Education to the said corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, it required.Please note that tenders are called for bonds redeemable according to the above table only, and that offers for short-term bonds will not be considered.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at Ste.Thérèse.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanies by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The School Commissioners for the Municipality of the City of Ste.Thérèse agree not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after March 1st 1972, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: October 27, 1961 \u2014 $147,500 \u2014 loan renewal; November 23, 1971 \u2014 89,000 \u2014 refinancing costs.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Thursday, February 17, 1972, at 8:00 o'clock p.m., at J.L.Blanchard Pavillcn, 6 Tassé Street, City of Ste.Thérèse, County of Terrebonne, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Ste.Thérèse (County of Terrebonne), January 19, 1972.Raymond Thibault, Secretary-Treasurer.J.L.Blanchard Pavilion, 6 Tassé Street, City of Ste.Thérèse (Terrebonne), P.Q.Telephone: 430-2200, code 514.44318 Town of Pointe-Gatineau County of Hull Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Louis Lamarche, Town Clerk, at the Town Hall, 17 Jacques-Cartier Street, Pointe-Gatineau, County of Hull, P.Q., until 8:00 o'clock, p.m.on Thursday, February 17, 1972, for the purchase of a bond issue of $1,530,500'for the Town of Pointe-Gatineau, County of Hull dated March 1, 1972 and redeemable serially from September 1, 1973 to September 1,1991 inclusive, 1100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 tembre 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur â 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-annui'llement les 1er septembre el 1er man de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mars 1972.Tableau d'amortissement \u2014 SI ,630,600 \u2014 19 ans Année Capital 1er septembre 1973.$ 50,500 1er septembre 1974 .54,000 1er septembre 1975 .58,000 1er septembre 1976 .63,000 1er septembre 1977 .69,000 1er septembre 1978 .76,000 1er septembre 1979 .82,000 1er septembre 1980.89,000 1er septembre 1981.98,000 1er septembre 1982 .60,000 1er septembre 1983.66,000 1er septembre 1984 .71,000 1er septembre 1985 .77.000 1er septembre 1986 .83,000 1er septembre 1987 .90,000 1er septembre 1988 .99.000 1er septembre 1989.106.000 1er septembre 1990.114,000 1er septembre 1991.125,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série du 1er septembre 1973 au 1er septembre 1982 avec le solde reporté au 1er septembre 1982.2° Obligations échéant en série du 1er septembre 1973 au 1er septembre 1987 avec le solde reporté au 1er septembre 1987.3° Obligations échéant en série du 1er septembre 1973 au 1er septembre 1982 avec le solde à terme fixe échéant le 1er septembre 1991.4° Obligations échéant en série du 1er septembre 1973 au 1er septembre 1982 avec le solde icporté au 1er septembre 1982 pour une partie et l'autre partie à terme fixe échéant le 1er septembre 1991.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe le 1er septembre 1991 ne devront pas être pour un montant inférieur à $125,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er septembre 1991.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et en devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable half-yearly on September 1st and March 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issueil at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from March 1, 1972.Redemption table \u2014 SI,530,600 \u2014 19 Years Year Capital September 1.1973.$ 50,500 September 1, 1974 .54.000 September 1, 1976 .58.000 September 1.1976.63,000 September 1,1977 .69.000 September 1, 1978 .76,000 September 1, 1979 .82, September 1, 1980 .89,000 September 1, 1981.98,000 September 1, 1982 .60,000 September 1, 1983 .66,000 September 1, 1984 .71,000 September 1, 1985 .77,000 September 1, 1986 .83,000 September 1.1987 .90,000 September 1, 1988 .99,000 September 1, 1989.106,000 September 1, 1990.114,000 September 1, 1991.125,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.September 1, 1973 to September 1, 1982 séria' bonds with the balance carried forward to September 1.1982.2.September 1, 1973 to September 1, 1987 serial bonds with the balance carried forward to September 1, 1987.3.September 1, 1973 to September 1, 1982 serial bonds with the balance as September 1, 1991 fixed-term bonds.4.September 1, 1973 to September 1, 1982 serial lionds with the balance carried forward to September 1, 1982 for the one part and the other part as September 1, 1991 fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the Septcmlicr 1, 1991 fixed-term bonds should not be for an amount less than $125,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of September 1, 1991.However, tenders should be sent for one only of the above methods of issue, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.k 1101 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Pointe-Gatineau.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto et à Ottawa, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetablcs par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe échéant le 1er septembre 1991 pour un montant supérieur à $125,000 et seul cet excédent sera racheta-ble par anticipation, au pair, le 1er septembre de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un ¦ chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Pointe-Gatineau s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er mars 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 269 \u2014 $69,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 272 \u2014 $47,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 441 \u2014 $89,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 454 \u2014 $535,000 \u2014 construction d'un complexe municipal; 460 \u2014 $100,000 \u2014 achat de machinerie; 462 \u2014 $165,000 \u2014 voirie; 469 \u2014 $175,000 \u2014 voirie; 477 \u2014 $350,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue, jeudi, le 17 février 1972, à 8 heures du soir.Hôtel de ville, 17, me Jacques-Cartier, Pointe-Gatineau, comté de Hull, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Pointe-Gatineau (Comté de Hull), ce 20 janvier 1972.Le greffier, Louis Lamarche.Hôtel de ville, 17, rue Jacques-Cartier, Pointe-Gatineau, (Hull), P.Q., Téléphone: 777-2796, code 819.44321-0 Avis divers Ville de Vaudreuil Avis public est par les présentes donné que la ville de Vaudreuil propose de se prévaloir de l'article 430 de la Loi des cités et villes lequel se lit comme suit: « Les rues ou ruelles ouvertes au public depuis au moins dix ans deviennent propriété de la municipalité dès que sont accomplies les formalités suivantes: 1.Le conseil approuve par résolution une description de toutes rues ou nielles ou de toute partie de celles-ci.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at Pointe-Gatineau.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head offices of the said bank in Toronto and Ottawa, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as September 1, 1991 fixed-term bonds for an amount greater than $125,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on September 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Pointe-Gatineau agrees not to bring out new bonds on the Canadian market within the sixty days upon, from and after March 1, 1972, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 269 \u2014 $69,000 \u2014 loan renewal; 272 \u2014 $47,500 \u2014 loan renewal; 441 \u2014 $89,000 \u2014 aqueduct, sewers roads; 454 \u2014 $535,000 \u2014 construction of a municipal complex; 460 \u2014 $100,000 \u2014 purchase of machinery; 462 \u2014 $165,000 \u2014 roads; 469 \u2014 $175,000 \u2014 roads; 477 \u2014 $350,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the council or of one of its committees, as the ease may be, to be held on Thursday, February 17, 1972, at 8:00 o'clock, p.m., at the Town Hall, 17 Jacques-Cartier Street, Pointe-Gatineau, Countv of Hull, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Pointe-Gatineau (County of Hull), January 20, 1972.Louis Lamarche, Town Clerk.Town Hall, 17 Jacques-Cartier Street, Pointe-Gatineau, (Hull), P.Q., Telephone: 777-2796, code 819.44321 Miscellaneous Notices Town of Vaudreuil Public notice is hereby given that the town of Vaudreuil proposes to avail itself of section 430 of the Cities and Towns Act which read as follows: \"The streets or lanes open to the public for ten years or more shall become the property of the municipality upon the observance of the following formalities: 1.The council shall approve by resolution a description of all streets or lanes or parts thereof with respect 1102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10i- année, n° l pour lesquelles la municipalité entend se prévaloir du présent article; 2.Cette description doit être faite d'après un plan cadastral et un livre de renvoi faits et déposés conformément à la loi du cadastre (chapitre 320); 3.L'original de cette description doit être déposé au bureau du greffier de la municipalité et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau du registrateur de la division d'enregistrement où se trouvent les terrains visés; 4.Le greffier de la municipalité fait publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal quotidien circulant dans la municipalité, avec un intervalle d'au moins trois mois et d'au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant: a) le texte intégral du présent article, 6) une description sommaire des rues ou ruelles concernées, c) une déclaration à l'effet que les formalités prévues aux paragraphes 1 et 2 ont été accomplies.Tout droit auquel des tiers pourraient prétendre à la propriété du fonds desdites rues ou ruelles est prescrit s'il n'est pas exercé par action devant le tribunal compétent dans l'année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec.La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l'égard de rues ou ruelles sur lesquelles elle a prélevé une taxe au cours des dix années précédentes.» En conséquence: 1.Le conseil de la ville de Vaudreuil a adopté à une assemblée tenue le 14e jour de décembre 1970, conformément à l'article 430 de la Loi des cités et villes ci-dessus reproduite, la résolution No 70-597 approuvant les documents suivants: a) plan No 9284-1 en date du 14 octobre 1971.b) plan No 9284-2 préparé par l'arpenteur-géomètre Jacques Demers le 29 avril 1968 et revisé par l'arpen-teur-géomètre Jean Charles Legault le 14 octobre 1970.c) descriptions techniques en date du 30 octobre 1970 toutes préparées par Jean Charles Legault, A.G.La description sommaire des rues concernées et montrées aux plans peut se résumer comme suit: A) Les rues suivantes faisant partie du cadastre officiel du village St-Michel de Vaudreuil: 1.Esther Blondin: étant une partie du lot 210.2.St-Jean Baptiste: sans désignation cadastrale.3.St-Michel: sans désignation cadastrale.4.St-Louis: sans désignation cadastrale.5.Ste-Angélique: n) sans désignation cadastrale; 6) étant le lot 144; c) étant une partie du lot 44.6.Ste-Julie: a) sans désignation cadastrale; b) étant le lot 181; c) étant une partie du lot 44.7.St-Joseph: a) sans désignation cadastrale; 6) sans désignation cadastrale; c) sans désignation cadastrale; d) sans désignation cadastrale; to which the municipality proposes to avail itself of this section; 2.Such description shall be made according to an official plan and book of reference made and deposited in conformity with the Cadastre Act (Chapter 320); 3.The original of such description must be deposited in the office of the clerk of the municipality and a copy certified by a land surveyor shall be deposited in the office of the registrar of the registration division where the lands concerned are situated; 4.The clerk of the municipality shall cause to be published twice in the Québec Official Gazette and in a daily newspaper circulating in the municipality, with an interval of not less than three months nor more than four months between publications, a notice containing: (a) the full text of this section; (6) a summary description of the streets or lanes concerned ; (c) a declaration to the effect that the formalities prescribed by paragraphs 1 and 2 have been observed.Any right that third parties might claim to the ownership of the site of the said streets or lanes shall be prescribed unless exercised by suit before the competent court within one year after the last publication in the Québec Official Gazette.The municipality cannot avail itself of this section with respect to streets or lanes on which it has levied any tax within the preceding ten years.\" Consequently : 1.The council of the town of Vaudreuil adopted, at a meeting held on December 14, 1970, in conformity with section 430 of the Cities and Towns Act quoted above, resolution No.70-597 approving the following documents: (a) Plan No.9284-1 dated October 14, 1971.(6) Plan No.9284-2 drawn up by Jacques Demers, land-surveyor, on April 29, 196S and revised by Jean Charles Legault, land-surveyor on October 14, 1970.(c) tcclinical descriptions dated October 30, 1970, entirely prepared by Jean Charles Legault, i.s.A description of the streets concerned and shown on the plans may be summarized as follows: (A) The following streets forming part of the official cadastre of the village of St.Michel de Vaudreuil: 1.Esther Blondin: forming a part of lot 210.2.St.Jean Baptiste: without cadastral designation.3.St.Michel: without cadastral designation.4.St.Louis: without cadastral designation.5.St.Angélique: (a) without cadastral designation; (6) forming lot 44 ; (c) forming a part of lot 44.6.St.Julie: (a) without cadastral designation; (6) forming lot 181; (c) forming a part of lot 44.7.St.Joseph: (a) without cadastral designation; (6) without cadastral designation; (c) without cadastral designation; ( CITÉ ET DU DISTRICT DE t MONTRÉAL, demanderesse, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.Un emplacement ayant front sur la 19ième rue, en la Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision six cent cinquante-cinq du lot deux cent soixante-quinze (275-655) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin, mesurant quarante pieds de largeur par une profondeur de quatre-vingt-quinze pieds, et contenant une superficie de trois mille huit cents pieds carrés (3,800 p.c), mesure anglaise.Avec la bâtisse dessus construite portant les numéros 141 et 143 de ladite 19ième rue, dont le mur sud-ouest est mitoyen.Sujet aux servitudes en faveur de Gaz Métropolitain, Inc., enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 278344; en faveur de La Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de La Commission Hydroélectrique de Québec permettant An emplacement fronting on Fontenay Street, in the City of Laval (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, known and described as being subdivision six hundred and thirty-one of original lot two hundred and seventy-five (275-631) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, containing four thousand thirty-seven and five-tenths square feet (4,037.5 sq.ft.), English measure.With the building under construction numbered 582 and 584 on the said Fontenay Street, the southeast wall of which is common.Subject to a servitude in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said companies to erect their posts, wires, cables, etc., registered in the Division of Laval Registry Office under number 279388; tu a servitude and agreement of servitude in favor of Gaz Métropolitain, Inc., allowing the said company to install its system for the distributing of gas, etc., registered at the said registry office under numbers 278344 and 279916 respectively, and a reciprocal servitude of right of view, the said servitude to be executed and registered shortly at the Division of Laval Registry Office.As the whole now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry Office.155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the EIGHTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal.January 12, 1972.44289 Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal ( THE MONTREAL CITY AND DIS-No.810-130.S -\u2022\u2022 TRICT SAVINGS BANK, plain-1 tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement fronting on 19th Street, in the City of Laval (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, known and described as being subdivision six hundred and fifty-five of lot two hundred and seventy-five (275-655) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, measuring forty feet in width by a depth of ninety-five feet, containing three thousand eight hundred square icet (3,800 sq.ft.), English measure.With the building constructed thereon numbered 141 and 143 on the said 19th Street, the southwest wall of which is common.Subject to the servitudes in favor of Gaz Métropolitain, Inc., registered at the Division of Laval Registry Office under number 278344; in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said companies to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10i, No.I 1113 auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles, etc., et à une servitude réciproque de droits de vue, lesdites servitudes en dernier lieu mentionnées devant être exécutées et enregistrées incessamment audit bureau d'enregistrement de la division de Laval.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement, avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 boulevard Je Me Souviens, à Laval, le HUITIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures TRENTE de lavant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44290-o Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-138.4 *-> CITÉ ET DU DISTRICT DE t MONTRÉAL, demanderesse, vs PARA-VERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.Un emplacement de forme irrégulière ayant front sur la rue de Dreux, en la Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision deux cent quarante et un du lot deux cent soixante-huit (268-241) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin et ayant une superficie de quatre mille quatre cent soixante et onze pieds carrés (4,471 p.c.) mesure anglaise.Avec la bâtisse en voie de construction qui portera les numéros civiques 336-338-340 rue de Dreux, Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides).Sujet à une servitude en faveur de La Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de La Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles, etc., le tout tel qu'établi aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 252743.Sujet également à une servitude en faveur de la Corporation de Gaz Naturel du Québec permettant à ladite compagnie d'installer ses canalisations pour la distrubution du gaz, etc., le tout tel qu'établi aux termes d'un acte devant être exécuté incessamment et enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Laval.Avec et sujet à une servitude réciproque de droits de vue établie par destination de père de famille aux termes d'un acte de servitudes reçu devant L.André Bourbeau, notaire, enregistré audit bureau d'enregistrement sous le numéro 276365.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement, avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 boulevard Je Me Souviens, à Laval, le HUITIÈME jour de MARS 1972 à TROIS heures de l'après-midi.Bureau du Shérif, L» shérif adjoint.Cour Supérieure.Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44297-o erect their posts, wires, cables, etc., and to a reciprocal servitude of right of view, the said servitudes lastly mentioned to be executed and registered shortly at the said Division of Laval Registry Office.As the said immoveable now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the EIGHTH day of MARCH, 1972, at TEN THIRTY in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court.Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44290 Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal ( MONTREAL CITY AND DIS- No.810-138.-) A TRICT SAVINGS BANK, plain-l tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement of an irregular configuration fronting on Dreux Street, in the City of Laval (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, known and described as being subdivision two hundred and forty-one of lot two hundred and sixty-eight (26S-241) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, containing four thousand four hundred and seventy-one square feet (4,471 sq.ft.), English measure.With the building under construction which will be numbered 336-338-340 Dreux Street, City of Laval (formerly Laval-des-Rapides).Subject to a servitude in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said companies to erect their posts, «ires, cables, etc., the whole as established in the terms of a deed registered at the Division of Laval Registry Office under number 252743.Also subject to a servitude in favor of the Quebec-Natural Gas Corporation allowing the said company to install its gas distribution systems, etc., the whole as established in the terms of a deed to be executed and registered shortly at the Division of Laval Registry Office.With and subject to a recriprocal servitude of right of view set up by the previous owner according to the terms of a deed of servitude executed before L.André Bourbeau, Notary, registered at the said registry office under number 276365.As the said immoveable now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the EIGHTH day of MARCH, 1972, at THREE o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44297 1114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10b' année, n° b Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal { T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-133.S -L- CITÉ ET DU DISTRICT DE l MONTRÉAL, demanderesse, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.Un emplacement ayant front sur la 19ième rue, en la Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision six cent cinquante-deux du lot deux cent soixante-quinze (275-652) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin, mesurant quarante pieds de largeur par une profondeur de quatre-vingt-quinze pieds, et contenant une superficie de trois mille huit cents pieds carrés (3,800 p.c), mesure anglaise.Avec la bâtisse dessus construite portant les numéros 155 e 157 de ladite 19ième rue, dont le mur nord-est est mitoyen.Sujet aux servitudes en faveur de Gaz Métropolitain, Inc., enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 278344; en faveur de La Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de La Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles, etc., et à une servitude réciproque de droits de vue, lesdites servitudes en dernier lieu mentionnées devant être exécutées et enregistrées incessamment audit bureau d'enregistrement de la division de Laval.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement, avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 boulevard Je Me Souviens, à Laval, le HUITIÈME jour de MARS 1972, à ONZE heures TRENTE de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44292-0 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal C T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-131.-) Lj CITÉ ET DU DISTRICT DE l.MONTRÉAL, demanderesse, M PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.« Un emplacement ayant front sur la place de Beaucaire, en la Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides), Province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision six cent soixante-sept du lot originaire numéro deux cent soixante et quinze (275-667) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin et contenant une superficie de trois mille huit cent pieds carrés (3,800 p.c), mesure anglaise.Avec la bâtisse en voie de construction, portant les numéros 508 et 510 de ladite place de Beaucaire, dont le mur nord-ouest est mitoyen.Sujet à une servitude en faveur de la Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de la Commission Hydro- Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal C THE MONTREAL CITY AND DIS-No.810-133.S 1 TRICT SAVINGS BANK, plain-l tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement fronting on 19th Street, in the City of Laval (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, known and described as being subdivision six hundred and fifty-two of lot two hundred and seventy-five (275-652) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, measuring forty feet in width by a depth of ninety-five feet, containing, three thousand eight hundred square feet (3,800 sq.ft).English measure.With the building constructed thereon numbered 155 and 157 on the said 19th Street, the northeast wall of which is common.Subject to the servitudes in favor of Gaz Métropolitain, Inc., registered at the Division of Laval Registry Office under number 278344, in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said companies to erect their posts, wires, cables, etc., and a reciprocal servitude of righ of view, the said servitudes lastly mentioned to be executed and registered shortly at the said Division of Laval Registry Office.As the said immoveable now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the EIGHTH day of MARCH, 1972, at ELEVEN THIRTY o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44292 Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal ( THE MONTREAL CITY AND DIS-No.810-131.{ 1 TRICT SAVINGS BANK, plain-l tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis cn cause.\"An emplacement fronting on Place de Beaucaire, in the City of Laval (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, known and described as being subdivision six hundred and sixty-seven of original lot number two hundred and seventy-five (275-667) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, containing three thousand eight hundred square feet (3,800 sq.ft.), English measure.With the building under construction numbered 508 and 510 on said Place de Beaucaire, the northwest wall of which is common.Subject to a servitude in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10k, No.k 1115 électrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles, etc., enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 279388; à une servitude et à un consentement de servitude en faveur de Gaz Métropolitain, Inc., permettant à ladite compagnie d'installer ses canalisations pour la distribution du gaz, etc., enregistrés audit bureau d'enregistrement sous les numéros 278344 et 279916 respectivement et à une servitude réciproque de droits de vue, ladite servitude devant être exécutée et enregistrée incessamment audit bureau d'enregistrement de la division de Laval.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement, avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 Boul.Je Me Souviens, à Laval, le HUITIÈME jour de MARS 1972, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44291-0 Commission allowing the said companies to erect their posts, wires, cables, etc., registered at the Division of Laval Registry Office under number 279388; to a servitude and a promise of servitude in favor of Gaz Métropolitain, Inc., allowing the said company to install its system for the distributing of gas, etc., registered in the said registry .office under numbers 278344 and 279916 respectively and to a reciprocal servitude of right of view, the said servitude to be executed and registered shortly at the said Division of Laval Registry Office.As the said immoveable now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.\" To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the EIGHTH day of MARCH, 1972, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assista?it Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44291 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-136.< *-* CITE ET DU DISTRICT DE l MONTRÉAL, demanderesse, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.Un emplacement ayant front sur la rue de Fontenay, de la Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision six cent trente-six du lot originaire deux cent soixante-quinze (275-636) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin et contenant une superficie de quatre mille trente-sept pieds carrés et cinq dixièmes de pied carré (4,037.5 p.c), mesure anglaise.Avec la bâtisse en voie de construction portant les numéros 558 et 560 de ladite rue de Fontenay, dont le mur nord-ouest est mitoyen.Sujet à une servitude en faveur de La Companie de Téléphone Bell du Canada et de la Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles, etc., enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 279388; à une servitude et à un consentement de servitude en faveur de Gaz Métropolitain, Inc.permettant à ladite compagnie d'installer ses canalisations pour la distribution du gaz, etc., enregistrés audit bureau d'enregistrement sous les numéros 278344, 278631 et 279916 respectivement et à une servitude réciproque de droits de vue, ladite servitude devant être exécutée et enregistrée incessamment audit bureau d'enregistrement de la division de Laval.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement, avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 boulevard Je Me Souviens, à Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal ( THE MONTREAL CITY AND DIS-No.810-136.S 1 TRICT SAVINGS BANK, plain-1 tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement fronting on Fontenay Street, in the City of Laval, (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, known and described as being subdivision six hundred and thirty-six of original lot two hundred and seventy-five (275-636) in the official plan and book of reference of the parish of St.Martin, containing four thousand thirty-seven and five tenths square feet (4,037.5 sq.ft.), English measure.With the building under construction numbered 558 and 560 on the said Fontenay Street, the northwest wall of which is common.Subject to a servitude in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said ctmpanies to erect their posts, wires, cables, etc., registered at the Division of Laval Registry Office under number 279388; to a servitude and agreement of servitude in favor of Gas Métropolitain, Inc., allowing the said company to install its system for the distributing of gas, etc., registered at the said registry effice under numbers 278344, 278631 and 279916 respectively and to a reciprocal servitude of right of view, the said servitude to be executed and registered shortly at the said Division of Laval Registry Office.As the whole now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the EIGHTH 1116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 29 janvier 1912, 10k' année, n° k Laval, le HUITIÈME jour de MARS 1972 à DEUX heures de l'après-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44295-0 day of MARCH, 1972, at TWO o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44295 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal i T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-134.-C *-> CITÉ ET DU DISTRICT DE V MONTRÉAL, demanderesse, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.Un emplacement ayant front sur la rue de Fontenay, en la Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision six cent vingt-neuf du lot originaire deux cent soixante-quinze (275-629) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin et contenant une superficie de cinq mille six cent quatre-vingt-huit pieds carrés (5,688 p.c.), mesure anglaise.Avec la bâtisse en voie de construction portant les numéros 592 et 594 de ladite rue de Fontenay, dont le mur sud-est est mitoyen.Sujet à une servitude en faveur de La Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de la Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles etc., enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 279388; à une servitude et à un consentement de servitude en faveur de Gaz Métropolitain Inc., permettant â ladite compagnie d'installer ses canalisations pour la distribution du gaz, etc., enregistrés audit bureau d'enregistrement sous les numéros 278344 et 279916 respectivement et à une servitude réciproque de droits de vue, ladite servitude devant être exécutée et enregistrée incessamment audit bureau d'enregistrement de la division de Laval.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement, avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 boulevard Je Me Souviens, à Laval, le HUITIÈME jour de MARS 1972, â DOUZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44293-0 Fieri Facias de Terris Superior Court\u2014 District of Montreal I THE MONTREAL CITY AND DIS-No.810-134.< 1 TRICT SAVINGS BANK, plain-l tiff, M PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement fronting on Fontenay Street, in the City of Laval (formerly Laval-des-Rapides), Proviuce of Québec, known and described as being subdivision six hundred and twenty-nine of original lot two hundred and seventy-five (275-629) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, containing five thousand six hundred and eighty-eight square feet (5,688 sq.ft.), English measure.With the building under construction numbered 592 and 594 on the said Fontenay Street, the southeast wall of which is common.Subject to a servitude in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said companies to erect their posts, wires, cables, etc., registered at the Division of Laval Registry Office under number 279388; to a servitude and agreement of servitude in favor of Gaz Métropolitain, Inc., allowing the said company to install its system for the distributing of gas, etc., registered at the said registry office under numbers 278344 and 279916 respectively and to a reciprocal servitude of right of view, the said servitude to be executed and registered shortly at the said Division of Laval Registry Office.As the said immoveable now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the EIGHTH day of MARCH, 1972, at TWELVE o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44293 Fieri Facias de Terris Com Supérieure \u2014 District de Montréal C T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-135.i CITÉ ET DU DISTRICT DE 1 MONTRÉAL, demanderesse, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.Un emplacement ayant front sur la 19e rue, en la Ville de Laval, (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, connu et.désigné comme étant la sub- Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal ( THE MONTREAL CITY AND DIS-No.810-135* A TRICT SAVINGS BANK, plain-v tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement fronting on 19th Street, in the City of Laval, (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, known and described a 9 being subdivision six QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10i, No.I 1117 division six cent cinquante-quatre du lot deux cent soixante-quinze (275-654) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin, mesurant quarante pieds de largeur par une profondeur de quatre-vingt-quinze pieds, et contenant une superficie de trois mille huit cents pieds carrés (3,800 p.c), mesure anglaise.Avec la bâtisse dessus construite portant les numéros 145 et 147 de ladite 19e rue, dont le mur nord-est est mitoyen.Sujet aux servitudes en faveur de Gaz Métropolitain, Inc., enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 278344; en faveur de La Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de La Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles, etc., et à une servitude réciproque de droits de vue, lesdites servitudes en dernier lieu mentionnées devant être exécutées et enregistrées incessamment audit bureau d'enregistrement de la division de Laval.Ainsi que ledit immeuble se trouve-présentement, avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 Boul.Je Me Souviens, à Laval, le HUITIÈME jour de MARS 1972, à DOUZE heures TRENTE de l'après-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44294 hundred and fifty-four of lot two hundred and seventy-five (275-654) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, measuring forty feet in width by a depth of ninety-five feet, containing three thousand eight hundred square feet (3,800 sq.ft.), English measure.With the building constructed thereon numbered 145 and 147 on the said 19th Street, the northeast wall of which is common.Subject to the servitudes in favor of Gas Métropolitain, Inc., registered at the Division of Laval Registry Office under number 278344 in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said companies to erect their posts, wires, cables, etc., and to a reciprocal servitude of right of view, the said servitudes lastly mentioned to be executed and registered shortly at the said Division of Laval Registry Office.As the said immoveable now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the EIGHTH day of MARCH, 1972, at TWELVE THIRTY in the afternoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44294 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-139.< ^ CITE ET DU DISTRICT DE l MONTRÉAL, demanderesse, M PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.Un emplacement ayant front sur la rue de Nieul, en la Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, connu et désigné comme étant la redivision deux cent quarante-trois du lot deux cent soixante-huit (268-243) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin, mesurant quarante-cinq pieds de largeur et quatre-vingt-dix pieds de profondeur, mesure anglaise.Avec la bâtisse en voie de construction portant les numéros 481 et 483 de ladite rue de Nieul, dont le mur nord-ouest est mitoyen.Sujet à une servitude en faveur de la Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de la Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles, etc., le tout tel qu'établi aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 252743.Avec et sujet à une servitude réciproque de droits de vue établie par destination de père de famille aux termes d'un acte de servitude reçu devant L.André Bourbeau, notaire, le vingt-cinq juin 1969.Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal i THE MONTREAL CITY AND DIS-No.810-139.< -L TRICT SAVINGS BANK, plain-1 tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement fronting on Nieul Street, in the City of Laval (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, known and described as being redivision two hundred and forty-three of lot two hundred and sixty-eight (268-243) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, measuring forty-five feet in width and ninety feet in depth, English measure.With the building under construction numbered 481 and 483 of the said Nieul Street, the northwest wall of which is common.Subject to a servitude in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said compagnies to erect their posts, wires, cables, etc., the whole as established in the terms of a deed registered at the Division of Lava 1 Registry Office under number 252743.With and subject to a reciprocal servitude of right of view set up by the previous owner according to the terms of a deed of servitude executed before L.André Bourbeau, notary, on the twenty-fifth day of June, 1969. 1118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 39 janvier 1973, 10i' année, n° i Et sujet à une servitude en faveur de la Corporation du Gaz Naturel du Québec permettant à ladite compagnie d'installer ses canalisations pour la distribution du gaz, etc., le tout tel qu'établi aux termes d'un acte de servitude reçu devant A.Auclair, notaire.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement avec tous ses droits et dépendances, sans exception ni réserve.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 boulevard.Je Me Souviens, à Laval, le HUITIÈME jour de MARS 1972, à TROIS heures TRENTE de l'après-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44298-o And subject to a servitude in favor of the Québec National Gas Corporation allowing the said company to install its gas distribution systems, etc., the whole as established in the terms of a deed of servitude executed before A.Auclair, notary.As the said immoveable now subsists, with all its rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the EIGHTH day of MARCH, 1972, at THREE THIRTY o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44298 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal l j A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-194.< ¦L' CITÉ ET DU DISTRICT DE l MONTRÉAL, demanderesse, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.« Un emplacement ayant front sur la rue de Dreux, en la Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision deux cent quarante du lot deux cent soixante-huit (268-240) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin et ayant une superficie de trois mille six cent pieds carrés (3,600 p.c.) mesure anglaise.Avec la bâtisse en voie de construction qui portera les numéros civiques 330-332-334 rue De Dreux, Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides).Sujet à une servitude en faveur de la Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de la Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, cables, etc., le tout tel qu'établi aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 252743.Sujet également à une servitude en faveur de la corporation de Gaz Naturel du Québec permettant à ladite compagnie d'installer ses canalisations pour la distribution du gaz, etc., le tout tel qu'établi aux termes d'un acte devant être exécuté incessamment et enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Laval.Avec et sujet à une servitude réciproque de droits de vue établie par destination de père de famille aux termes d'un acte de servitudes reçu devant L.André Bourbeau, notaire, enregistré audit bureau d'enregistrement sous le numéro 276365.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 Boul.Je Me Souviens, à Laval, le NEUVIÈME jour de MASS 1972, à DEUX heures de l'après-midi.Bureau du Shérif, Ta shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44309-o Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal I THE MONTREAL CITY AND DIS-No.810-194.{ -I TRICT SAVINGS BANK, plain-l tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement fronting on Dreux Street, in the City of Laval (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, known and described as being subdivision two hundred and forty of lot two hundred and sixty-eight (268-240) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, containing three thousand six hundred square feet (3,600 sq.ft.), English measure.With the building under construction which will be numbered 330-332-334 Dreux Street, City of Laval (formerly Laval-des-Rapides).Subject to a servitude in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said companies to erect their posts, wires, cables, etc., the whole as established in the terms of a deed registered at the Division of Laval Registry Office under number 252743.Also subject to a servitude in favor of the Québec Natural Gas Corporation allowing the said company to install its gas distribution systems, etc., the whole as established in the terms of a deed to be executed and registered shortly at the Division of Laval Registry Office.6 \" With and subject to a reciprocal servitude of right of view set up by the previous owner according to the terms of a deed of servitude executed before L.André Bourbeau, notary, registered at the said registry office under number 276365.As the said immoveable now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the NINTH day of MARCH, 1972, at TWO o'clock p.m.Sheriff's Office, pACL St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44309 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.I 1119 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-140.< -L* CITE ET DU DISTRICT DE v MONTRÉAL, demanderesse, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.Un emplacement ayant front sur la rue de Fontenay, en la Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision suc cent quarante-sept du lot originaire deux cent soixante-quinze (275-647) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin et contenant une superficie de trois mille huits cent pieds carrés (3,800 p.c), mesure anglaise.Avec la bâtisse en voie de construction portant les numéros 563 et 565 de ladite rue de Fontenay, dont le mur sud-est est mitoyen.Sujet à une servitude en faveur de La Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de la Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles, etc., enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 279388; à une servitude et à un consentement de servitude en faveur de Gaz Métropolitain, Inc.permettant à ladite compagnie d'installer ses canalisations pour la distribution du gaz, etc., enregistrés audit bureau d'enregistrement sous les numéros 278344 et 279916 respectivement et à une servitude réciproque de droits de vue, ladite servitude devant être exécutée et enregistrée incessamment audit bureau d'enregistrement de la division de Laval.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement, avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 boulevard Je Me Souviens, à Laval, le HUITIÈME jour de MARS 1972, à QUATRE heures de l'après-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44299-0 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal C T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-141.4 CITÉ ET DU DISTRICT DE l MONTRÉAL, demanderesse, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.Un emplacement ayant front sur la 19e rue, en la Ville de Laval, (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, contenant une superficie de quatre mille cent soixante-dix-sept pieds carrés (4,177 p.c), mesure anglaise, et composé de: a) La subdivision six cent cinquante-sept du lot deux cent soixante-quinze (275-657) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin; et Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal I THE MONTREAL CITY AND DIS-No.810-140.< -L TRICT SAVINGS BANK, plain-l tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement fronting on Fontenay Street, in the City of Laval (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, known and described as being subdivision six hundred and forty-seven of original lot two hundred and seventy-five (275-647) in the official plan and book of reference of the parish of St.Martin, containing three thousand eight hundred square feet (3,800 sp ft.), English measure.With the building under construction numbered 563 and 565 of the said Fontenay Street, the southeast wall of which is common.Subject to a servitude in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said companies to erect their posts, wires, cables, etc., registered at the Division of Laval Registry Office under number 279388; to a servitude and an agreement of servitude in favor of Gaz Métropolitain, Inc., allowing the said company to install its gas distribution systems, etc., registered at the said registry office under numbers 278344 and 279916 respectively and to a reciprocal servitude of right of view, the said servitude to be executed and registered shortly at the said Division of Laval Registry Office.As the said immoveable now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the EIGHTH day of MARCH, 1972, at FOUR o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44299 Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal ( T™ MONTREAL CITY AND DIS-No.810-141.S 1 TRICT SAVINGS BANK, plain-l tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement fronting on 19th Street, in the City of Laval, (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, containing four thousand one hundred and seventy-seven square feet (4,177 sq.ft.), English measure and composed of : (a) Subdivision six hundred and fifty-seven of lot two hundred and seventy-five (275-657) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin; and 1120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 39 janvier 1973, 104' année, n' i b) La subdivision trois cent quatre-vingt-treize du lot deux cent quatre-vingt-cinq (285-393) auxdits plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin.Avec la bâtisse dessus construite portant les numéros 131 et 133 de ladite 19e rue, dont le mur sud-ouest est mitoyen.Sujet aux servitudes en faveur de Gaz Métropolitain, Inc., enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 278344; en faveur de La Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de La Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles, etc., et à une servitude réciproque de droits de vue, lesdites servitudes en dernier lieu mentionnées devant être exécutées et enregistrées incessamment audit bureau d'enregistrement de la division de Laval.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement, avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du compté de Laval, 155 Boul.Je Me Souviens, à Laval, le NEUVIÈME jour de MARS 1972 à NEUF heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44300-O Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal t T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-142.< -L- CITE ET DU DISTRICT DE t MONTRÉAL, demanderesse, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.Un emplacement ayant front sur la rue de Beaucaire, en la Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision trois cent quatre-vingt-seize du lot originaire deux cent quatre-vingt-cinq (285-396) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin et contenant une superficie de cinq mille quatre cent quatorze pieds carrés (5,414 p.c), mesure anglaise.Avec la bâtisse en voie de construction, portant les numéros 462 et 464 de ladite rue de Beaucaire, dont le mur sud-est est mitoyen.Sujet à une servitude en faveur de la Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de la Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles, etc., enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 279388; à une servitude en faveur de Gaz Métropolitain, Inc.permettant à ladite compagnie d'installer ses canalisations pour la distribution du gaz, etc., enregistrée audit bureau d'enregistrement sous le numéro 278344 et à une servitude réciproque de droits de vue, ladite servitude devant être exécutée et enre-tistrée incessamment audit bureau d'enregistrement de la division de Laval.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement, avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.(b) Subdivision three hundred and ninety-three of lot two hundred and eighty-five (285-393) in the said official plan and book of reference of the Parish of St.Martin.With the building constructed thereon numbered 131 and 133 of the said 19th Street, the southwest wall of which is common.Subject to the servitudes in favor of Gaz Métropolitain, Inc, registered at the Division of Laval Registry Office under number 278344; in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said companies to erect their posts, wires, cables, etc., and to a reciprocal servitude of right of view, the said servitudes lastly mentioned to be executed and registered shortly at the said Division of Laval Registry Office.As the said immoveable now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the NINTH day of MARCH, 1972, at NINE in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44300 Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal { THE MONTREAL CITY AND DIS-No.S10-142X L TRICT SAVINGS BANK, plain-l tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement fronting on Beaucaire Street, in the City of Laval (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, known and described as being subdivision three hundred and ninety-six of original lot two hundred and eighty-five (285-396), in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, containing five thousand four hundred and fourteen square feet (5,414 sq.ft.), English measure.With the building under construction number 462 and 464 of the said Beaucaire Street, the southeast wall of which is common.Subject to a servitude in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said companies to erect their posts, wires, cables, etc.registered at the Division of Laval Registry Office under number 279388; to a servitude in favor of Gaz Métropolitain, Inc, allowing the said company to install its gas distribution systems, etc., registered at the said registry office under number 2/8344 and to a reciprocal servitude of right of view, the said servitude to be executed and registered shortly at the said Division of Laval Registry Office.As the said immoveable now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.4 1121 Pour être vendu-au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 boulevard Je Me Souviens, à Laval, le NEUVIÈME jour de MARS 1972 à NEUF heures TRENTE de lavant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44301-O To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the NINTH day of MARCH, 1972, at NINE THIRTY in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44301 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal { T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No .810-191.< CITÉ ET DU DISTRICT DE \\ MONTRÉAL, demanderesse, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.« Un emplacement de forme irrégulière ayant front sur la rue de Dreux, en la Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, faisant partie des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin, ayant une superficie de quatre mille six cent vingt-six pieds carrés (4,626 p.c.) et composé de: a) La subdivision deux cent vingt-six du lot deux cent soixante-huit (268-226) audits plan et livre de renvoi officiels; b) La subdivision cent seize du lot deux cent soixante-sept (267-116) auxdits plan et livre de renvoi officiels; Les mesures ci-dessus sont en mesure anglaise.Avec la bâtisses en voie de construction qui portera les numéros civiques 342-344-346 rue de Dreux, Ville de Laval (Autrefois Laval-des-Rapides).Sujet à une servitude en faveur de La Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de la Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles etc., le tout tel qu'établi aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 252743; Sujet également à une servitude en faveur de la Corporation de Gaz Naturel du Québec permettant à ladite compagnie d'installer ses canalisations pour la distribution du gaz, etc., le tout tel qu'établi aux termes d'un acte devant être exécuté incessamment et enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Laval.Avec et sujet à une servitude réciproque de droits de vue établie par destination de père de famille aux termes d'un acte de servitudes reçu devant L.André Bourbeau, notaire, enregistré audit bureau d'enregistrement sous le numéro 276365.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement, avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 boulevard Je Me Souviens, à Laval, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DOUZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44307-o Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal { THE MONTREAL CITY AND DIS-No.810-191.4 -L TRICT SAVINGS BANK, plain-( tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.\"An emplacement of an irregular configuration fronting on Dreux Street, in the City of Laval (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, being part of the official plan and book of reference of the parish of St.Martin, containing four thousand six hundred and twenty-six square feet (4,626 sq.ft.) composed of: (a) Subdivision two hundred and twenty-six of lot two hundred and sixty-eight (268-226) in the said official plan and book of reference; (6) Subdivision one hundred and sixteen of lot two hundred and sixty-seven (267-116) in the said official plan and book of reference; The measurements hereinabove are English measure.With the building under construction which will be numbered 342-344-346 Dreux Street.City of Laval formerly Laval-des-Rapides).Subject to a servitude in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said companies to erect their posts, wires, cables, etc.the whole as established in the terms of a deed registered at the division of Laval Registry Office under number 252743; Also subject to a servitude in favor of the Québec Natural Gas Corporation allowing the said company to install its gas distribution systems, etc., the whole as established in the terms of a deed to be executed and registered shortly at the division of Laval Registry Office.With and subject to a reciprocal servitude in right of view set up by the previous owner according to the terms of a deed of servitude executed before L.André Bourbeau, notary, registered at the said registry office under number 276365.As the said immoveable now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.\" To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the NINTH day of MARCH, 1972, at TWELVE o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44307 1122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, lui- année, n° 4 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-145.4 ¦Lj CITÉ ET DU DISTRICT DE l MONTRÉAL, demanderesse, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.Un emplacement ayant front sur la rue de Fontenay, en la Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision six cent trente du lot originaire deux cent soixante-quinze (275-630) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin et contenant une superficie de quatre mille trente-sept pieds carrés et cinq dixièmes de pied carré (4,037.5 p.c), mesure anglaise.Avec la bâtisse en voie de construction portant les numéros 58S et 590 de ladite rue de Fontenay, dont le mur nord-ouest est mitoyen.Sujet à une servitude en faveur de La Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de la Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles, etc., enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 279388; à une servitude et à un consentement de serviturle en faveur de Gaz Métropolitain, Inc., permettant à ladite compagnie d'installer ses canalisations pour la distribution du gaz, etc., enregistrés audit bureau d'enregistrement sous les numéros 278344 et 279916 respectivement et à une servitude réciproque de droits de vue, ladite servitude devant être exécutée et enregistrée incessamment audit bureau d'enregistrement de la division de Laval.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement, avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 boulevard Je Me Souviens, à Laval, le NEUVIÈME jour de MARS 1972 à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44304-o Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal t T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-200.') *-> CITE ET DU DISTRICT DE l MONTRÉAL, demanderesse, tu PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.Un emplacement ayant front sur la 19ième Rue, en la Ville de Laval, (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision six cent einquante-six du lot deux cent soixante-quinze (275-656) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin, mesurant quarante pieds de largeur par une profondeur de quatre-vingt-' quinze pieds, et contenant une superficie de trois mille huit cents pieds carrés (3,800 p.c), mesure anglaise.Fieri Facias de Terris Superior Court\u2014 District of Montreal I '-THE MONTREAL CITY AND DIS-No.810-145.4 A TRICT SAVINGS BANK, plain-1 tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement fronting on Fontenay Street, in the City of Laval (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, known and described as being subdivision six hundred and thirty of original lot two hundred and seventy-five (275-630) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, containing four thousand and thirty-seven and five tenths square feet (4,037.5 sq.ft.), English measure.With the building under construction numbered 588 and 590 of the said Fontenay Street, the northwest wall of which is common.Subject to a servitude in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Company allowing the said companies to erect their posts, wires, cables, etc., registered at the Division of Laval Registry Office under number 279388; to a servitude and an agreement of servitude in favor of Gaz Métropolitain, Inc., allowing the said company to install its gas distribution systems, etc., registered at the said Registry Office under numbers 278344 and 279916 respectively and to a reciprocal servitude of right of view, the said servitude to be executed and registered shortly at the said Division of Laval Registry Office.As the whole now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry.Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the NINTH day of MARCH, 1972, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court.Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44304 Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal t THE MONTREAL CITY AND DIS-No.810-200.4 J- TRICT SAVINGS BANK, plain-' tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC., defendant, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement fronting on 19lh Street, in the City of Laval, (formerly Laval-des-Rapides), Province of Quebec, known and described as being subdivision six bundled and fifty-six of lot two hundred and seventy-five (275-656) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, measuring forty feet in width by a depth of ninety-five feet, containing three thousand eight hundred square feet (3,800 sq.ft.), English measure. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January S9, 197S, Vol.101, No.4 1123 Avec la bâtisse dessus construite portant les numéros 135 et 137 de ladite 19ième Rue, dont le mur nord-est est mitoyen.Sujet aux servitudes en faveur de Gaz Métropolitain, Inc., enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 278344; en faveur de La Compagnie de Téléphone Bell du Canada et de La Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles, etc., et à une servitude réciproque de droits de vue, lesdites servitudes en dernier lieu mentionnées devant être exécutées et enregistrées incessamment audit bureau d'enregistrement de la division de Laval.Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement, avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval.155 boulevard Je Me Souviens, à Laval, le DIXIÈME jour de MARS 1972 à NEUF heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 12 janvier 1972.44314-o With the building erected thereon numbered 135 and 137 of the said 19th Street, the northeast wall of which is common.Subject to the servitudes in favor of Gaz Métropolitain, Inc., registered at the Division of Laval Registry Office under number 278344; in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said companies to erect their posts, wires, cables, etc., and a reciprocal servitude of right of view, the said servitudes lastly mentioned to be executed and registered shortly at the said Division of Laval Registry Office.As the said immoveable now subsists, with all rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the TENTH day of MARCH, 1972, at NINE o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44314 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal C T A BANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 810-192.-) *-> CITÉ ET DU DISTRICT DE V MONTRÉAL, demanderesse, ta PARAVERT CONSTRUCTION INC., défenderesse, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.Un emplacement ayant front sur la rue de Dreux, en la Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides), province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision neuf cent cinquante du lot deux cent soixante et onze (271-950) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin et ayant une superficie de trois mille six cents pieds carrés (3,600 p.c), mesure anglaise.Avec la bâtisse en voie de construction qui portera les numéros civiques 306-308-310 rue de Dreux, Ville de Laval (autrefois Laval-des-Rapides).Sujet à une servitude en faveur de la compagnie de Téléphone Bell du Canada et de la Commission Hydroélectrique de Québec permettant auxdites compagnies d'ériger leurs poteaux, fils, câbles, etc., le tout tel qu'il est établi aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Laval sous le numéro 252743.Sujet également à une servitude en faveur de la Corporation de Gaz Naturel du Québec permettant à ladite compagnie d'installer ses canalisations pour la distribution du gaz, etc., le tout tel qu'établi aux termes d'un acte devant être exécuté incessamment et enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Laval.Avec et sujet à une servitude réciproque des droits de vue établie par destination de père de famille aux termes d'un acte de servitude reçu devant L.André Bourbeau, notaire, enregistré audit bureau d'enregistrement sous le numéro 276365.Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal l 'T'HE MONTREAL CITY AND DIS-No.810-192.-) i- TRICT SAVINGS BANK, plain- v tiff, vs PARAVERT CONSTRUCTION INC.defendant, and THE REGISTRAR ot the Registration Division of Laval, mis en cause.An emplacement fronting on Dreux Street, in the City of Laval (formerly Laval-des-Rapides), Province of Québec, known and described as being subdivision nine hundred and fifty of lot two hundred and seventy-one (271-950) in the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, containing three thousand six hundred square feet (3,600 sq.ft.), English measure.With the building under construction which will be numbered 306-308-310 Dreux Street, City of Laval (formerly Laval-des-Rapides).Subject to a servitude in favor of the Bell Telephone Company of Canada and the Québec Hydro-Electric Commission allowing the said companies to erect their posts, wires, cables, etc., the whole as established in the terms of a deed registered at the Division of Laval Registry Office under number 252743.Also subject to a servitude in favor of the Québec Natural Gas Corporation allowing the said company to install its gas distribution systems, etc., the whole as established in the terms of a deed to be executed and registered shortly at the Division of Laval Registry Office.With and subject to a reciprocal servitude of right of view set up by the previous owner according to the terms of a deed of servitude executed before L.André Bourbeau, notary, registered at the said Registry Office under number 276365. 1124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Ainsi que ledit immeuble se trouve présentement avec tous droits et dépendances, sans exception ni réserve.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 boulevard Je Me Souviens, à Laval, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DOUZE heures TRENTE de l'après-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal.12 janvier 1972.44308-o As the said immoveable now subsists with all rights and dependencies, without exception or reservation.To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, the NINTH day of MARCH, 1972, at TWELVE THIRTY o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 12, 1972.44308 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal C.S.M.t T A BANQUE D'ÉPARGNE DE 05-811-970-71.< -M LA CITE ET DU DISTRICT 5 21*' southe,l9t: by P' 180 and p- l82; northwest: by Le secrétaire-trésorier.Paix O.Despatis, 44320-4-2-o Paul O.Despatis.44320-4-2-o Secretary-Treasurer. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.104, No.I 1153 IIV D E X No 4 Partiel: avis juridiques \u2014 Parti: Juridical notices ASSOCIATION COOPÉRATIVE COOPERATIVE ASSOCIATION Association coopérative forestière de St-Alphonse {Slat, ch.).1077 AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Estate of Arthur Girard (Benefit of inventory).1103 Estate of Gabriel Paquette (Benefit of inventory).1103 Estate of Claude Robert (Benefit of inventory).1104 Montréal, ville-city (Rachat a\" obligations-Redemption of bonds no 80).1104 Succession Arthur Girard (Bénéfice d'inventaire).1103 Succession Gabriel Paquette (Bénéfice d'inventaire).1103 Succession Claude Robert (Bénéfice d'inventaire).1104 Vaudreuil, ville-town.1101 CHANGEMENT DE NOM \u2014Loi du CHANGE OF NAME ACT Demandes: Applications: Biron (dit Raymond) Joseph.1061 Carmellv, Felicia Steigman Hefter.1060 Gitlitz, William.1060 Plesoeanu, Dan Virgil.1061 Yampolsky (Pollack), Julie.1061 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Accordés: Granted: Briand, Joseph René.1059 Campbell, Lynden Maynard Bruce.1059 Carmeli, Suzan.1059 Dostie, Marie Clara Noëlla Pauline.1059 Grey, Julius Henry.1059 Packer, Jack.1060 Rothschild, Henri Charles.1060 Smiley, Stanley.1060 CAISSES D'ÉPARGNE SAVINGS AND COMPANIES EXTRA-PROVINCIAL ET DE CRÉDIT CREDIT UNIONS ÉTRANGÈRES COMPANIES Caisse populaire Desjardins de Beloeil (La) Changement d'agent: Change of Agent: (Mod.terr.).1076 Trans-American Collections, Inc.1076 Caisse populaire de Louiseville (La) (Mod.terr.).1076 Siège social: Head Office Ideal Bay Explorations Limited.1075 COMMISSION COMMISSION rwBS mmmdimrV Municipale Québec Municipal COMPAGNIES- COMPANIES de Québec Commission LAJl Uns Al,l _ .,, 1 Demandes d'abandon Applications for Bagotville yille-town {Plus en tutelle-no longer de charte Surrender of Charter m default).who St-Henri-de-Taillon, munie.(Plus en tutelle- Albany Investment Corporation.1C62 no longer in default).1078 Allied International Products Inc.1062 St-Jérôme village (Plus en tutelle-no longer in Amyot (A.D.) inc.1061 default) .1078 Barry Children's Wear Inc.1063 Ste-Geneviève^ vilie-town (Plus en tutelle-no Bonnaire Mortgage Corporation.1062 longer in default).1078 Boulangerie F.Doyon & Fils ltee.1061 1154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 104' année, n° 4 Demandes d'abandon Applications for de charte Surrender of Charter (suite) (continued) Centre d'achats ouvrier (Montréal) inc.1062 Compagnie de gestion J.Noël Tessier inc.(La) 1063 Comptoir du jardin inc.1062 Delvoye (R.) Inc.1063 Entreprises Korvette ltée (Les).1064 Gauvreau Machinery & Supply Limited.1064 Neptal Properties Limited.1064 Placements F.B.L.inc.1064 Rubin Investment Corp.1063 Sévigny (Adélard) inc.1065 Station Viauville Inc.(The).1064 Textile Promotions Ltd.1063 Dissoutes Dissolved Beau-Der Inc.1051 Bijouterie Jean B.Roy ltée.1052 Blouin (Jos.) Alimentation inc.1052 Bolduc & Frères ltée.1052 Brimak Inc.1052 Canada Auto Leasing Co.Ltd.1052 Canadian Steel Limited.1052 Club de Tennis de Joliette inc.(Le).1053 Da Pasquali Restaurant, Inc.1053 Entreprises B.C.M.ltée (Les).1053 Hillsdale Investment Corp.1053 L.S.G.Realties Corp.1053 Périka Construction Inc.1053 Prodor Inc.1054 Stein (P.J.) Inc.1054 Techlem Inc.1054 Théâtre Frontenac limitée.1054 Divers Miscellaneous Aéro-Club de St-Hubert (Règl.).1065 Alimentation Lemelin inc.(Dir.).1066 Association des diplômés M.B.A.(Laval) (Règl.-By-laws).1065 Boutique Corinne inc (Nom-Name ch.).1066 Club social de Ste-Marie inc.(Règl.-By-laws).1066 Collective Investments Inc.(Dir.).1065 Collège Marie de France (Dir.)-.1066 Concours de musique du Québec inc.(Les) (Nom ch.).1066 Conseil de vie étudiante du collège de Chicoutimi inc.(Règl.-By-laws).1067 Conseil régional des loisirs de Québec (Règl.- By-laws).1067 Côte-Nord sportif inc.(Dir.).1066 Industries Larco ltée (Les) (Dir.).1068 Jobin (Réjean) auto inc.(Nom-Name ch.).1067 Larco Industries Ltd.(Dir.).1068 Limited Parternship Services (Montreal) Inc.(Nom-Name ch.).1067 Loman Inc.(Dir.).1069 Michelin Upholstering Ltd.(Name ch.).1067 Mirage St-Hyacinthe inc.(Dir.).1068 Mobilier Vie-Line inc.(Nom ch.).1068 Placements collectifs inc.(Les).1065 Productions librefilms inc.(Les) (Dir.).1068 Québec Music Competitions Inc.(Name ch.).1066 Rembourrage Michelin ltée (Nom ch.).1067 St.Hubert Flying Club (By-laws).1065 Service des loisirs de Saint Jean-de-Matha de Montréal incorporé (Le) (Dir.).1065 Union théâtrale de Sherbrooke inc.(L') (Règl- By-laws).1068 Vic-Line Furniture Inc.(Name ch.).1068 United Services Club Ltd.(The) (Règl.-By- laws).1068 Lettres patentes Letters Patent Agence d'assurance Pantazis, Assimakopoulos, Pantazis inc.(L').1020 Alfa-Omega Distributing Co.Ltd.1005 Alter (Phil) Sales Inc.1005 Aménagements Revcon limitée (Les).1030 Assurances Clinton inc.1008 Baillargeon (Paul) Productions Inc.1005 Balls Jeans Ltd.1006 Brendan Wood & associés (Québec) ltée.1038 Burton's Importing Inc.1006 Café André inc.1007 Cana Explorations Limited.1007 Canaper Holdings Ltd.1007 Centre du Cyclisme Peel ltée.1022 Chapotal Corporation.1008 Clinton Insurance Inc.1008 Colossus Land Investments Corp.1009 Corporation de Gestion Guy Fortier, ltée.1012 Cypihot Gym Equipment Inc.1009 Dan River Mining & Exploration Inc.1009 Dave's Quality Meat Inc.1010 De Vimy Pictures Ine.1010 Elite Screen Process Company Ltd.1010 Équipement de gymnase Cypihot inc.1009 Excavation Q-M ltée.1026 Famous Delly House Inc.1011 Fadon Corporation.1011 Fastat Inc.1012 Fernando's Delicatessen Inc.1012 Fortier (Guy) Holding Corporation Ltd.1012 Fournitures d'Hôpitaux Québec ltée.1027 Greenberg (S.) & Assoc.Ltd.103fr Guardsman Equipment Leasing (Québec) Ltd.1013 Guybrooke Trading Inc.1013 H.K.Truck & Trailer Inc.1014 H.R.H.Investments Ltd.1014 Hanbec Inc.1014 Hank's Restaurant Inc.1015 Harem Restaurant Inc.1015 Harley Plaza Restaurant Inc.1016 Hartco Inc.1016 Hayward & Son Ltd.1016 Immeubles Vadar inc.(Les).1036 Importations Burton inc.1066 Institutional Management and Supply Corporation .1017 Koran 'Explorations Limited.1017 Kotai Music Inc.1018 Krauspe (H.A.) (1971) Ltd.1018 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.10i, No.i 1155 Lettres patentes Letters Patent (.suite) (continued) Lacordaire Restaurant Ltd.1030 Lexington Enterprises Ltd.1018 Magasin descompte Place St-Jean inc.1025 Monoghan Mining Corporation (Québec) Limited.1019 Musique Kotai inc.1018 Optex Inc.1019 Optimum Distribution Services Incorporated.1020 Orville & Wilbur Fly Inc.1020 Pantazis, Assimakopoulos, Pantazis Insurance Agency Inc.1020 Paper Place of Westmount Inc.(The).1021 Paramount Paper Products Ltd.1021 Peel Cycle Center Ltd.1022 Pejay Construction Inc.1022 Pereira International (Canada) Ltd.1022 Peters Mines Ltd.1023 Picken Service Inc.1023 Pincourt Restaurants Inc.1024 Place Aylmer inc.1024 Placements Bijar ltée (Les).1024 Place St-Jean Discount Store Inc.1025 Preferred Leasebacks Limited.1025 Provisions St-Benoit inc.1025 Q-M Excavation Ltd.1026 Quadrant Construction Ltd.1026 Québec Hospital Supplies Ltd.1027 Quincaillerie J.R.Ravary ltée.1027 R.& A.Photo Vision Inc.1027 R & W Paper Converters Inc.1028 Ramona Music School Inc.1028 Rebico Investments Inc.1029 Rennat Enterprises Limited.1029 Restaurant Don Quichotte inc.1029 Restaurant Lacordaire ltée.1030 Restaurants Pincourts inc.1024 Revcon Developments Limited.1030 Richmill Enterprises Ltd.1031 Robstan Enterprises Limited.1031 S.C.S.Industries Corp.1031 S & M Restaurant & Hotel Equipment Co.Ltd.1032 St.Benoit Provisions Inc.1025 Salaberry Auto Body Inc.1032 Scene Diversified Products Corp.1032 Seabro Corporation.1033 Sécurité Ito inc.1033 Sergio Realties Inc.1034 Seton Development Ltd.1034 Sherelco Inc.J035 Shuchat Franchises (Drummondville) Inc- 1035 South Eastern Gas & Oil Ltd.1036 Vadar Realties Inc.1036 Variety Discount Fabrics Inc.1036 Ventes Phil Alger inc.1005 Viauville Tire Ltd.1037 W.H.H.Investments Ltd.1037 Warshaw Wholesale Inc.1037 West-Island Estates Inc.1038 Wood (Brendan) & Associates (Québec) Ltd.1038 Zasarsky's Restaurant Inc.1039 Lettres patentes Letters Patent avis d'annulation notice of annulment Glendale Industries Ltd.1074 Valleyfield Adjustment Bureau Ltd.1075 Lettres patentes Letters Patent supplémentaires supplementary African Safari Park (Québec) Inc.1039 Air Ste-Agathe inc.1039 Air-Vision Industries Inc.1040 Beauward Shopping Centres Ltd.1040 Blue Star Trading Ltd.1040 Broderick (J.) Service Ltd.1041 Centres d'Achats Beauward ltée (Les).1040 Club Social de Ville-Émard.1041 Consolidated-Bathurst Pulp and Paper Limited .1041 Corporation de Primes d'Assurance E-Z (La) 1042 Dixville Home Inc.1041 E-Z Insurance Premium Corporation.1042 Firm Root Investment Corp.1042 General Customs Brokers Inc.1042 Gerbro Corp.1042 Gervais Chair & Table Ltd.1043 Gervais Chaise & Table ltée.1043 Graham Secretarial College Inc.1043 Greek Social Centre Inc.1043 Greenshields Ltd.1043 Halliday, Dubé Lumber Company.1044 Hanger (Mr) (Québec) Inc.1C44 Hatton (Ken) Associates Limited.1044 Hawco Construction Ltd.1044 Heartlands Inc.1045 Industries Air-Vision inc.(Les).1040 International Railway Publishing Company (Limited).1045 Jardins Caprice inc.1045 Josel Realty Corp.1045 Keenan-Eccles Printing Co.Ltd.1046 Kurland (Léonard) Inc.1046 Lafave (W.J.) & Fils ltée.1046 Lafave (W.J.) & Sons Ltd.1046 Leader Industries Ltd.1046 Madeleine Investments Inc.1047 Manyan Trading Corp.1047 Maple Ridge Investment Ltd.¦.1047 Melran Corporation.1047 Montreal North Properties Ltd.1047 Murray & Company Inc.1048 Oak Investment Corp.1048 Pampero Fcod Products Inc.1048 Pare Safari African (Québec) inc.1039 Patella (Franz) Incorporated.1048 Pâtes et Papiers Consolidated-Bathurst limitée 1041 Placements Bretagne inc.1049 Placements Riviéra ltée.1049 Poplar Investments Inc.1049 Routeland Corporation.1049 Saratoga Slacks Mfg.Inc.1049 1156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10k' année, n° i Lettres patentes Letters Patent supplémentaires supplementary (suite) (continued) Service J.Broderick ltée.1041 Smiley's Super Market Ltd.1050 Smiley's Super Market Ltd.1050 Top Holdings Inc.1050 United Dental Supply Corporation.1050 Venice Realties Ltd.1051 Verchères Realties Ltd.1051 Wise Investments Ltd.1051 Siëges sociaux Head Offices Aqua Maintenance Inc.1069 Arts Valmont ltée (Les).1070 Bélanger, Philiberg & Sénécal inc.1070 Chantecler Wines Limited.1070 Cody-Chargo Ltd.1072 Cody-Chargo ltée.1072 Constructions Jean P.Hamelin inc.(Les) .1071 Côté-Nord sportil inc.1073 École de formation sportive de Grand'Mère inc.1073 Emotion Productions Inc.1074 Intosilem Inc.1074 Joly Construction Inc.1074 Lacombe et frère inc.1072 Melri Inc.1071 Multi-services professionnels (M.S.P.) Inc.1072 Opéra du Québec (L').1073 Papineau Machine Shop Inc.1071 Perruquier de Sherbrooke inc.(Le).1071 Productions émotion inc.1074 Proulx (G.) et associés, assurances inc.1072 St-Jean (Bernard) inc.1069 Samaro Trade Corporation.1069 Sheff, Weiser and Associates Inc.1070 Sheff, Weiser et associés inc.1070 Telemonde inc.1069 Varie Inc.1073 Vins Chantecler limitée (Les).1070 LIQUIDATION DES WINDING-UP COMPAGNIES \u2014 Loi de la ACT Comptoir avicole de St-Félix de Valois.1078 Magasin co-op de Trinité-des-Monts.1078 Société coopérative agricole de St-Michel de Squateck.1079 MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales Municipal Affairs Bic.munie.(Fusion volontaire-Voluntary amalgamation) .1080 Mont Gabriel, ville-town (Const.-Inc.).1083 Rimouski, cité-city (unité de regroupement arec-Regroupement unit with: village de Rimouski- Est et par.Ste-Anne-de-la-Pointe-au-Père.1082 Rimouski-Est, village (unité de regroupement avec-Regroupement unit with: cité de Rimouski et par.Ste-Anne-de-la-Pointe-nu-Père.1082 Ste-Anne-de-la-Pointe-au-Père, par.(unité de regroupement avec-Regroupment unit with: cité de Rimouski et village de Rimouski-Est).1082 Institutions Financial financières Institutions compagnies Companies et coopératives and Cooperatives Assurance: Insurance: Stabilité, compagnie d'assurance-vie (La) (Dem.de remise des valeurs).1077 Stability Life Insurance company (App.for return of securities).1077 Terres et forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Arthabaskaville, village.1054 Charlesbourg, par.1054 Charlesbourg, par.1055 Laflèche, canton-township.1055 Laprairie de la Magdaleine, par.1055 McKenzie, canton-township.1055 Mise à jour partielle du cadastre dans les paroisses de St-Augustin, St-Benoit, St-Canut, St-Hermas, St-Janvier, St-Jérôme, Ste-Scholastique et Ste-Thérèse de Blainville faisant partie des divisions d'enregistrement de Deux-Montagnes et Terrebonne.1058 Montréal, par.1056 Notre-Dame de l'Assomption de Repentigny, par.1056 Partial up-dating of the cadastre in the Parishes of St.Augustin, St.Benoit, St.Canut, St.Hcrmas, St.Janvier, St.Jérôme, St.Scholastique and St.Thérèse de Blainville forming part of the Two Mountains and Terrebonne Registration Divisions.1058 Québec, cité-city (Montcalm Quartier-Ward) 1055 Ste-Anne de la Pocatièrc, par.1056 St-Antoine de Longueuil, par.1056 St-Eustache, par.1056 St-Féréol, par.1057 St-Joseph du Lac, par.1057 St-Martin, par.1057 St-Philippe, par.1057 St-Romuald d'Etchemin, par.1057 Signai, canton-township.1057 Winslow, canton-township.1058 SOUMISSIONS \u2014 TENDERS \u2014 demandes de Requests for Bagotville, ville-town.1085 Cowansville, ville-town.1088 Douville, ville-town.1096 Pointe-Gatineau, ville-town.1099 Pont-Viau, c.s.-s.c.1090 Port-Cartier, c.s.-s.c.1087 St-Hubert, ville-town.1092 Ste-Thérèse, ville-town.1098 St-Rodrigue, cs.-s.c.1083 Shawinigan.cité-city.1094 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 29, 1972, Vol.101, No.1 1157 SYNDICATS PROFESSIONAL PROFESSIONNELS SYNDICATES Fédération des travailleurs du papier et de la forêt (Nom-Name ch.).1080 Fédération du Commerce inc.(CSN) (Nom-Name ch.).1079 Syndicat national des travailleurs des pâtes et papier de Joliette inc.(Nom-Name ch.).1079 VENTES SALES Par Shérifs By Sheriff's Hull Hull Société des artisans (La) VS Damien.1107 IbervUle Iberville Bienvenue vs Tétrault.1108 Kamouraska Lebel vs Lebel.Labelle Individual Investment Corp.vs Mahoney.Prévoyants du Canada (Les) vs Bélanger.Kamouraska .1108 Labelle .1109 .1135 Montréal Montreal Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.et al.1110 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.,.1111 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etoV.1111 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1112 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.et al.1113 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1114 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.,.1114 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) m Paravert Construction Inc.et of.-y 11,5 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1116 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) M Paravert Construction Inc.et Of.1116 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1117 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1118 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1119 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1119 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.et al.1120 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal:.1121 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction lue.etal.1122 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1122 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.et al.1123 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1124 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.et al.1125 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1125 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1126 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1127 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.et al.1127 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1128 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.eto/.1129 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1130 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.etal.1130 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Paravert Construction Inc.eto/.1131 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.et al.1110 Montreal City and District Savings Bank (The) M Paravert Construction Inc.et al.1111 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.et al .1111 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1972, 10k' année, n° j 1158 Montréal Montreal (tuile) (continued) Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1112 Montreal City and District Savings Bank (The) m Paravert Construction Inc.et al.1113 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1114 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.et al.1114 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1115 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1116 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1116 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1117 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.et al.1118 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1119 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1119 Montreal City and District Savings Bank (The) m Paravert Construction Inc.et al.1120 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1121 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.et al.1122 Montreal City and District Savings Bank (The) m Paravert Construction Inc.etal.1122 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.et al.1123 Montreal City and District Savings Bank (The) M Paravert Construction Inc.et al.1124 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.et al.1125 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.et al.1125 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1126 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1127 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.et al.1127 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1128 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.et al.1129 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1130 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Paravert Construction Inc.etal.1130 Montreal City and District Savings Bank (The) M Paravert Construction Inc.et al.1131 Québec Quebec Côté vs Aubé.1133 Dubrofsky M Labrêche.1133 Household Finance Corporation of Canada vs Dumontier.1132 Household Finance Corporation of Canada vs Lacelle.U32 Roberval Roberval Imperial Oil Ltd.m Tremblay.1134 Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda Bank of Montreal vs Deschamps.1134 Banque de Montréal vs Deschamps.1134 Taxes \" Taxes Anjou, c.s.-s.c.957 Arthabaska, comté-county.981 Bagot, comté-county.912 \u2022.Barkmere, ville-town.1139 Beaconsfield, cité-city.945 Beauce, comté-county.1002 Bellechasse, comté-county.800 Bcrtliier, comté-county.796 Bonaventure, comté-county.727 Brome, comté-county.720 Champlain, comté-county.985 Charlcvoix-Est-East, comté-county.860 Charlevoix, Ouest-West, comté-county.800 Châteauguay, comté-county.733 Chicoutimi, comté-county.864 Compton, comté-county.747 -Drummond, comté-county.1142 Deux-Montagnes, comté.840 Frontenac, comté-county.999 Gaspé-Est-East, comté-county.946 Gatineau, comté-county.772 Grand St-Martin, c.s.q.967 Greater St.Martin, p.s.b.967 Rjervillc, comté-county.979 Joliette, comté-county.699 Kamouraska, comté-county.916 Labelle, comté-county.850 Lac St-Jean-Ouest, comté.750 Lake St.John West, county.750 Laprairie, comté-county.689 L'Assomption, comté-county.920 \"-Laurenvale, c.s.p.-p.s.c.1140 Lévis, comté-county.755 L'Islet, comté-county.838 Lotbinière, comté-county.956 ~Maniwaki, ville-town.H36 Maskinongé, comté-county.931 Matapédia, comté county.
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.