Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 3 (no 44)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1973-11-03, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC PARTIE 1 AVIS JURIDIQUES OFFICIAL GAZETTE 3 NOVEMBRE 1973 N° 44 6363 PART 1 JURIDICAL NOTICES 6 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1973, 105' année, n\" U 6365 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Quebec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DTJBÉ, Québec Officiai Publûher 6366 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.106, No.U TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion : 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère a notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation : $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20; from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité\" Parlementaire, Québec G1A 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105- année, n° U 6367 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 6a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names folfow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed A.B.C.DRIVESHAFT INC.A.C.IMPORT INC.,.L'ACIER RAY NO INC.AETNA MECHANICAL PLUMBING INC.AGENCE POPULAIRE DE FINANCEMENT INC.L'AQENCE UN TOIT INC.LES AGENCES CAPITAINE ROBERT INC.LES AGENCES CARTIER-LAURIER LTEE.AIR THETFORD LIMITEE.ALCAN CLUB.AMERICANA MOTEL CORP.L'ASSOCIATION DES AMIS DE LA FAUNE DE HULL INCORPOREE.L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES ENSEIGNANTS ITALO-CANADIENS.L'ASSOCIATION DES MARCHANDS D'AUTOS BRITANNIQUES.L'ASSOCIATION DES MARCHANDS DE VERDUN INC.L'ASSOCIATION MONSEIGNEUR DE LAVAL.L'ASSOCIATION DES NORMALIENS DE JACQUES-CARTIER INC.ASSOCIATION DES PARENTS GRECS-ORTHODOXES (HELLENIQUE) DE L'ECOLE CARLYLE.L'ASSOCIATION DES PHOTOGRAPHES DE LA PRESSE DE QUEBEC.L'ASSOCIATION DES POLICIERS-POMPIERS DE VICTORIAVILLE INC.L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES TECHNICIENS EN LOISIR DU QUEBEC INC.ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE MOTELS DE MONTREAL INC.Montreal.1960 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1968 à/to 1973 incl.Longueuil,.1971 à/to 1973 incl.Longueuil.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Rivière-du-Loup.1972 et/and 1973 Hull.1966 à/to 1973 incl.Thetford-Mines.1972 et/and 1973 Montréal.1971 et/and 1973 Montreal.1967 à/to 1973 incl.Hull .1965.1966, 1969 et/and 1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Verdun.1971 et/awd 1973 St-Joachim.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Québec.1965 à/to 1973 incl.Victoriaville.1955,1964 à/to 1970 incl-, 1972 et/and 197» Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl. 6368 QUÉBEC OFFICIAI GAZETTE, November 3, 1973.Vol.105.AT», ii Nom de la compagnie Name of the company ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE STE-MARTHE-DU-CAP-DE-LA-MADELEINE INC.L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE TERRAIN DE CAMPING DE LA COTE-DU-SUD INC.ASSOCIATION SPORTIVE DE REPENTIGNY INC.ASSOCIATION SPORTIVE ST-FRANÇOIS INC.ASSOCIATION SPORTIVE DE LA VILLE DE LAPRAIRIE.L'ASSOCIATION DES SPORTS ET LOISIRS DE VAUDREUIL-SOULANGES INC.LES ASSURANCES BOUGIES 4 ASSOCIES INC.LES ASSURANCES G.LAMBERT INC.LES ASSURANCES HARVEY & GAGNON INC.AU BOUCLIER DE BRENNUS INC.AU DOMAINE JOLY INC.AU PIED DE COCHON (1971) INC.AU VALON FORESTIER (1965) INC.AUX PETITS FOURS INC.L'AUBERGE DES MONTAGNAIS INC.L'AUBERGE RUSTIQUE, INC.AUTO ENTERPRISES MONTREAL LTD.AUTOMOBILE DE L'EST INC.B.A F.METAL WORKS LTD.B & F REALTIES CO.LTD.B.T.0.HEATING INC.BILLY'S INC.LE BOUCAN INC.FELIX BOUCHARD INC.BOUCHERIE MONTREAL-NORD LTEE.BOULANGERIE BARIL INC.BOULANGERIE FLEURY LIMITEE.LE BOULEVARD DU CARNAVAL INC.BOULEVARD ESTATES CORP.JEAN-GUY BOURCIER INC.BOURGEOIS ELECTRIQUE LTEE.BOURGET MOTEL CORP.LES BOURGUIGNONS DE JOLIETTE INC.Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Ste-Marthe-du-Cap-de- 1967 à/to 1973 incl.la-Madeleine.St-Jean-Port-Joli.1967.19G9.1971 et/and 1973 Kepentigny.1971 à/to 1973 incl.Laval.1969 ù/to 1973 incl.Laprairie.1967 à/to 1973 incl.Vaudreuil.1966, 1967.1969 à/to 1973 incl.Laval.1970 à/to 1973 incl.Joliette.1970 à/to 1973 incl.Jonquière.1964 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1971 et/and 1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl.Lessee.1965 à/to 1973 incl.Montréal-Est.1968 à/to 1973 incl.Sept-Iles.1971 à/to 1973 incl.Gatineau.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966,1969 à/to 1971 incl.et/and 1973 Montreal.1968, 1972 et/and 1973 Montréal.1961 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1967 à/to 1973 incl.Bois-des-Filion.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1969 à/to 1973 incl- Rouyn.1966, 1967.1969 à/to 1973 incl.L'Ascension.1962 à/to 1966 incl., 1968 à/to 1973 incl.Québec.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1959.1965, 1968 à/to 1973 incl.Mercier.1971 à/to 1973 incl.St-André-Avellin.1964.1966.1967, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Joliette.1966, 1969 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973.105' année.v° U C369 Nom de la compagnie Name of the Company LA BOUSSOLE DE MONTREAL INC.BOUTIQUE DU BEBE INC.BOUTIQUE FRANFRELUCHE INC.LES BOUTIQUES MES AMIS LES ANIMAUX INC.BOWIE INSURANCE AGENCY INC.BOWLING EQUIPMENT & REPAIRS INC.JEAN BOYER INC.'.D.S.BRADLEY (CANADA) LTD.BltADNER FUR CO.LTD.BRAL INC.BRANDED ENTERPRISES LIMITED.BRANDED HOSIERY SALES (MONTREAL) LTD.PIERRE I'.BRAULT INC.BRENDAN WOOD & ASSOCIATES LTD.BRENMORE QUÉBEC MINES LIMITED.PAUL W.BRENNER INC.BRESCO IMPORT EX PORT CO.LTD.BRICON REALTIES INC.BRIQUE ET PIERRE DU QUEBEC LTEE.BRITISH & AMERICAN CARS LTD.BROADMORE SERVICE CORPORATION.BROME ESTATES INC.BROMERIDGE LTD.BROME-SHEFFORD DEVELOPMENT CO.LTD.BROSS FURS INC.J.V.BROSSARD AUTO PARTS VALLEYFIELD INC.BROWN BROS.AUTO PARTS INC.RICHARD M.BROWN CONSTRUCTION LTD.BROWN-WINLOW COMPANY LIMITED.YVAN BRUNET INC.BUBBLE TOY SALES AND PROMOTIONS LTD.BUILDERS MORTGAGE BROKERS INC.BURTON COLE (CANADA) LTD.LAWRENCE BURTON COMPANY LIMITED.BURTON SALES INC.BUSINESS EQUIPMENT LIMITED.Adresse Rapports non produits Addres» Returns not filed St-Lconard.1970 a/to 1973 incl.Donnaeona.1909 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Campbell's Bay.1964 à/to 1973 incl.Pointe-aux-Treinblea., .1966 à to 1973 incl.Westmount.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1962, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1960 / to 1973 incl.Montréal .1970 à/to 1973 incl.Montreal.1961, 1965 à/to 1973 incl.l'ointe-aux-Tremhles .1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Ville-Marie.1962.1963, 1965, 1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Mount Royal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1969, 1970.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1961.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Granby.1970 à/to 1973 incl.Knowlton.1972 et/and 1973 Sweetsburg.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Valleyfield.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Dorval.1965 à/to 1973 incl.Chomedey.1964 à/to 1973 incl.Montreal .1972 et/and 1973 Montreal.1961.1962, 1964 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1967, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 0370 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Nom de la compagnie Name of Ihe company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed 1HIWVKIJ, EQUIPMENT CO.LTD.BYWAY HOLDING COUP.LTD.CABARET CHEZ MAURICE INC.LE CABARET LITTERAIRE NELL1CAN INC.CABARET LORAINE INC.(ABIMAS INVESTORS INC.CADEAUX REGAL INC.CADRES PROFESSIONNELS INC.CAFE CASANOVA INC.CALLAN DEVELOPMENT INC____.CAMCLAIR INC.CAMDEB REALTIES LIMITED.CAMELOT DESIGN ASSOCIATES INC.CAMEO SILKS & DRAPERIES INC.CAMP DAN INC.CAMP HIAWATHA INC.CAMP L'ESCALE.CAMP SAINT-MAURICE DE DUVERNAY INC.Montreul Montreal Montréal Québec .Québec Montreal Montréal Montréal Montréal Montreal Montreal Montreal Montreal Montreal Montreal Montreal Montréal .Laval.CAM PANORAMA INC.Montreal CAMPAR INVESTMENT INC.PAUL CAM PEAU & FILS LTEE.Montreal.Salaberry-de-Valleyfield.CAMPER'S VILLAGE LTD.CAMPING CANADIEN (MONTREAL) INC.CAMPING HAVRE DES ILES INC.CAMPING 8T-EDMOND INC.Montreal Montréal Granby.St-Jean .CANADIAN CAMEO CHIME COMPANY LIMITED.CANADIAN HAT FRAMES LTD.CANADIAN A INTERNATIONAL FOOTWEAR INC.CANADIAN MAGNETIC INC.CANADIAN MOULDED PULP PRODUCTS.CANADIAN YOUTH BOYS' TOWN____ CAPITOL BUILDING CORPORATION.Montreal Montreal Préville.Montreal Laval.Montreal.Montreal.CAPITOL ENTERPRISES INC.Montreal.1962, 1964 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1963 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1967 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1963 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1963 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1938 à/to 1940 incl.1961, 1970 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1970 à/to 1973 incl.1966, 1967, 1968, 1970 à/to 1973 incl.1963, 1964, 1968 à/to 1973 incl.1959, 1961 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1967, 1969, 1971 à/to 1973 incl.1967, 1969, 1971 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1969, 1971 à/to 1973 incl.1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1060 à/to 1973 incl, GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 100' année, «\u2022 U 6371 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed LEO L.CAPLAN A CO.LTD.Montreal.1970 à/to 1973 incl.CAPRICORN PRODUCTIONS LTD.Montreal.1971 à/to 1973 incl.CARAVAN CONSTRUCTION (1969) LTD.Montreal.1969 à/to 1973 incl.CARBO-MIX OF CANADA (QUEBEC) LTEE.Montreal.1964, 1966 à/to 1973 incl.CARDI LTD.Montreal.1962 à/to 1973 incl.CARDINAL MOTEL INC.L'Ancienne-Lorette.1964 à/to 1973 incl.CARDTOWN LTD.Verdun.1971 à/to 1973 incl.CAR-ELL HOLDINGS INC.Montreal.1970 a/to 1973 incl.CARETTE AUTOS (CHICOUTIMI) LTEE.Chicoutimi.1972et/and 1973 CARIBBEAN LEISURE CORPORATION INC.CARIBOU LAND LTD.J.CARIN SALES CORPORATION.CARLTON HOUSING LTD.CARMELLY INSURANCE AGENCIES INC.CARMEN REALTIES INC.LE CARNAVAL D'ETE DES TROIS-RIVIERES INC.CARNAVAL DE GRANBY INC.LE CARNAVAL DE ST-JEAN INC.CAROLINE CREATIONS LTD.CARON CREIGHTON LTEE.CARON A GUILBAULT (CHAUFFAGE) INC.CAROSSERIES ISOTHERMES L'IGLOO LTEE.CARPEC INC.CARPET LAND OF MONTREAL INC.CARREFOUR DU LIVRE DE LACHUTE.CARRIER A FRERES CONSTRUCTION INC.CARRIERE DE TROIS-PISTOLES INCORPOREE.LES CARRIERES DE RIMOUSKI INC.CARROLS HOLDINGS LTD.LE CARROUSEL MURDOCH VILLE LTEE.CARSEY HOLDINGS LTD.JACQUES CARTIER INVESTMENTS CO.CARTIER METALS CORP.CARTIER PARKING INC.CARTIER VENDING LIMITED.CARVO LTEE.CATHELCO SYSTEMS (QUEBEC) LTD.Chomedey.1972 et/and 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 insl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Hull.1066 à/to 1973 incl.Trois-Rivicres.1969, 1972 et/and 1973 Granby.1966 à/to 1973 incl.St-Jean.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1967 incl.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.L'Ancienne-Lorette.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Québec.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Lachute.1972 et/and 1973 St-François.1971 à/to 1973 incl.Trois-Pistoles.1966 à/to 1973 incl.Rimouski.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1961, 1966 à/to 1973 incl.Murdoehville.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Chomedey.1965, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1968 à/to 1973 incl.Lachine.1964, 1967 à/to 1973 incl.St-Adolphe-d'Howard.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl. 6372 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973.Vol.105, No.U Nom de la compagnie Name of the company CAUCHON & FRKRES LTEE.LA CAVE DU MEUBLE INC.CAVEBEN LIMITEE.CAVENDISH CAFE INC.CENTRAL MANAGEMENT CORPORATION.CENTRE AUTO-NEIGE TEMI'LETON INC.CENTRE MARINE DU CAP INC.CENTRE RECREATIF ST-LUC INC.CENTRE DE SKI ET DE RECREATION CHATEAU BLEU INC.CENTURY AUTOMOTIVE CORPORATION.CERCLE DE BRIDGE \u2022 LE BOULEVARD ¦ INC.CHAUFFAGE ROBER FORTIN INC.CHEZ MAILLOUX INC.LA CIE BOI'RMA LTEE.LA CIE DE PLACEMENTS FINASCOM LTEE.CINEMA GOLF ST-MICHEL INC.CLOUTIER & BOURASSA CONSTRUCTION INC.CLUB DE L'AGE D'OR, MANIWAKI.CLUB DES BRICOLEURS EBENISTES DE ST-JOSEPH DE SOREL INC.CLUB DE CHASSE « CLEAR BROOK » D'ORMSTOWN.CLUB EL-PASO INC.LE CLUB DES FRANCS DE M AGOG INC.LE CLUB DU GARAGISTE INC.CLUB DE GOLF CARTIERVILLE INC.CLUB INTER-PROFESSIONNEL & EUREKA INC.LE CLUB DE MOTO-NEIGE LA TANIERE INC.CLUB OPTIMISTE MAISONNEUVE INC.CLUB PERSONNALITE MONTREAL-MAISON NEUVE.CLUB RICHELIEU GASPE INC.CLUB DE TIR DE BOUCHERVILLE INC.COIFFEUR POUR HOMMES VALCARTIER INC.COMFORT CARPET CORPORATION.COMITE DES LOISIRS DE SAINT-EUGENE INC.COMPAGNIE CAMAR LTEE.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1967 à/to 1973 incl.Anjou.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à.'to 1973 incl.Montreal.1965.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1962.1964.1971 à/to 1973 incl.Templeton.1970 à/to 1973 incl.Cap-de-la-Mndeleine.1970 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1967 et/and 1973 Montréal.1961.1971 à/to 1973 incl.Amos.1967 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.V.St-Laurent.1958.1963 à/to 1965 incl.1071 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1965, 1967 à.'to 1973 incl.Pointe-aux-Trembles .1969 à/to 1973 incl.Maniwaki.1973 St-Jo^epli-de-Sorel.1971 à/to 1973 incl.Ormstown.1966 à/to 1973 incl.Lachine.1970 à/to 1973 incl.Magog .1965.1970 à/to 1073 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1965.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Ste-Brigitte-de-Laval .1972 et/and 1973 Montréal.1965, 1966, 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1962 à/to 1965 incl.1970 à/to 1973 incl.Gaapé.1968 à/to 1973 incl.Boucherville.1970 à/to 1973 incl.Valcartier.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.St-Eugéne.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n° U 6373 Nom de la compagnie Name of the company LA COMPAGNIE DE PUBLICATION TRANS-GASPESIENNE LTEE.COMPTOIR D'INFORMATIONS TRANS-QUEBEC INC.LE CONSEIL DES LOISIRS DE CACOUNA INC.CONSOLIDATED BOWLING LTD.CONSTRUCTION FORM CO.LTD.CONSTRUCTION LOZARD INC.CONSTRUCTION LUCERNE INC.CONSTRUCTIONS CASMAR LIMITEE.LES CONSTRUCTIONS ELYSEE LTEE.CONTINENTAL MAINTENANCE INC.LA CORPORATION DU CENTRE MONT FORTIN INC.CORPORATION MANAGEX.LA CORPORATION DU TOURISME DE RIVIERE-DU-LOUP.CREDIT DES MARCHANDS INC.J.ROMEO CROTEAU LTEE.D & D PROPANE GAS & OIL INC.DAMES AUXILIAIRES DE L'HOPITAL DE LA PIETA.DASCO LTEE.DASMIC INC.DATAC LTD.DATAMATIC BOOKKEEPING SERVICE LIMITED.DATATECH INCORPORATED.DATSUN BOULEVARD INC.DAUPHIN IRON MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).DAVAR CONSTRUCTION INC.DAVIS-SISMONDO INC.DE LAVAL HOLDINGS & ENTERPRISES LTD.JEAN DEGUIRE ASSURANCE INC.DEHM INVESTMENTS INC.DEVELOPMENT CONSTRUCTION CO.LTD.LE DEVELOPPEMENT DES ILES CARILLON INC.DOMAINE MANSEAU INC.DONUT BOY INC.DUFRESNE & DURESNE INCORPOREE.E.M.R.HOLDINGS INC.Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Ste-Anne-des-Monts- 1968.1970 à/to 1973 incl.Victoriaville.1969 à/to 1973 incl.Cacouna.1972 et/and 1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Kamouraska.1972, 1973 Ste-Marguerite Station.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Duvernay.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Kénogami.1972, 1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl.Rivicre-du-Loup.1967, 1969 à/to 1973 incl.Laval.1968 à/to 1973 incl.Québec.1968 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1969 à/to 1973 incl.Hull.1967 à/to 1973 incl.Mont-Royal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1908 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.St-Laurent.1969 à/to 1973 incl.Sept-Iles.1970 à/to 1973 incl.Chibougamau.1966, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Coteau-du-Lac.1972.1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1961 incl., 1963 à/to 1965 incl.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.L'Abord-à-Plouffe.1961 à/to 1973 incl.St-Louis-de-Pintendre.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1969 incl.1972, 1973 6374 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Nom de la compagnie Name of the company E.S.O.N.LTEE.EASTERN CATERERS LTD.EASTERN FREIGHT FORWARDERS LTD.EASTERN PEAT MOSS INC.LES EDITIONS CADRES LTEE.ELKMEN DEVELOPMENT CORP.ELLAS CONSTRUCTION LTD.ELRAINE REALTY CORP.EMBASSY ESTATES CORP.EMBASSY MERCHANDISING MFG.LTD.EMGO REALTY CORP.EMILE CONSTRUCTION COMPANY LTD.EMPIRE ELECTRONICS INC.EMPIRE GEM INC.LES ENCHERES LEBRUN INC.ENDEMA CO.LTD.RAYMOND ENRIGHT ET ASSOCIES LTEE.LES ENTREPRISES BELLE FLAMME LTEE.LES ENTREPRISES BOURASSA LIMITEE.LES ENTREPRISES BOURGEOIS INC.LES ENTREPRISES BOURJAC OCTO LIMITEE.LES ENTREPRISES CHALIFOUX & BASTIEN INC.ENTREPRISES DAUBREE LIMITEE.LES ENTREPRISES DEL-CHAMP INC.LES ENTREPRISES ELECTRIQUES DE GAGNE INC.LES ENTREPRISES FORESTIERES DE STRATFORD INC.LES ENTREPRISES FORTIN & VILLENEUVE INC.ENTREPRISES GALEX LTEE.ENTREPRISES GEORGE FORTIN INC.ENTREPRISES M.P.G, LONGUEUIL INC.LES ENTREPRISES MAURICE BELANGER INC.LES ENTREPRISES MONT-ROYAL (1967) INC.LES ENTREPRISES MORISSET INC.LES ENTREPRISES DE L'OUEST INC.LES ENTREPRISES DE PEINTURE DE STE FOY INC.Adresse Rapports non produits Address Return) not filed Montréal.1972, 1973 Magog .1970 à/to 1973 incl.St.Léonard.1973 Burrough's Fall.1963.1964.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1966 incl.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1970, 1972, 1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1959.1964, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Farnham.1966 à/to 1973 incl.St-Laurent.1964, 1967.1969 à/to 1973 incl.Granby.1966 à/to 1973 incl.Villeneuve.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1964, 1971 à/to 1973 incl.Napierville.1965.1966, 1967.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Pointe-aux-Trembles.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Stratford.1972 et/and 1973 Pointe-au-Pic .1972 et/and 1973.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1068 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Verdun.1964 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1964 à/to 1973 incl. GAZETTK OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1973.105' aimée.,i° U 037.5 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Addreu Rapport non produits Rrturn» no tfiled LES ENTREPRISES STE-BRIO.ITTE LTEE.LES ENTREPRISES DE LA VALLEE DE L'OUTAOUAIS INC, LES ENTREPRISES WILKIN INC.EQUIPEMENTS DE BUREAUX LAUHENTIDE INC.L'ETOILE DE GASPE INC.LES ETOILES DE LONGUEUIL INC.ETRIMO INC.EUBIOS INC.EUROPEAN AGENCIES LTD.FEDERATION DES MOTOCYCLISTES DE SENTIERS DU QUEBEC.FEDERATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LONGUEUIL INC.LES FETES DE LA ST JEAN.FINANCIAL PLANNING COMPANY OF LATIN AMERICA LTD.FINEWAY 8PECIALTY INC.FIORITO ASSURANCE LIMITEE.FIRST NATIONAL BUILDING CORP.FITZJOHN INVESTMENTS LTD.FLAMING HEARTH INVESTMENTS LTD.FLAMINGO CONSTRUCTION INC.FLEETWOOD DEVELOPMENT CORP.FLEI8HERS WOOLLEN MILLS SUPPLIES LIMITED.FLEUR DE LYS CARPET CO.LTD.FLEXBETON LIMITED.LA FOIRE DU LIVRE DE MONTREAL INC.FONDATION CAROL BRILLANT INC.LA FONDATION RICHELIEU (ST-JEAN) INC.LE FONDS DE CHARITE CATHOLIQUE DE LACHINE.FONDS METROPOLITAINS INC.LA FONTAINE DU BOULEVARD LTEE.FORE8TVILLE CONSTRUCTION LTEE.FORGET AUTOMOBILES INC.FORMATION SPORTIVE HORIZON INC.Ste-Brigitte-des-Saults.1969 à/to 1971 incl., 1973 Hull.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Bhawialgan.1964.1966, 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Longueuil.1964 à/to 1973 incl.St-Laurenl.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Aima.1972.1973 Longueuil.1965, 1967 à/to 1973 incl.St-Pierre I.0.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1967.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1966.1967.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1964 incl.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1966.1971 à/to 1973 incl.St-Léonard.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1966.1971 à/to 1973 incl.Chomedey.1964 à/to 1973 incl.St-Pierre.1970 à/to 1973.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.St-Jean.1972, 1973 Lachine.1960.1961, 1962, 1964 à/to 1973 incl.St-Michel.1964, 1969 à/to 1973 incl.St-Félicien.1969 à/to 1973 incl.Forestville.1963 à/to 1973 incl.Montréal.1972 Montréal.1971 à/to 1973 incl. 6876 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 3.1973.Vol.105.No.U Nom de In compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed FORTENNA DEVELOPMENT & ASSOCIATES INC.LA FORTUNE PHOTO STUDIO INC.FOTO CANADA PUBLISHING CORPORATION.FOU II SEASON BUILDING MAINTENANCE INCORPORATED L.FOY INC.FOYER SAINT-CHRISTOPHE DE NEW CARLISLE INC.FOYER SAINT-FRANCOIS DE MONTMAGNY.FRAMA LIMITEE.FRAN RYE INVESTMENT CORPORATION.FRANCIBEC INC.FRANCO METAL LIMITEE.FRANKEL INC.FRAN MICHE INC.FRANORAM LTEE.FRANTIC INVESTMENTS INC.FRATERNITE FRANÇAISE.FREEGOLD MANAGEMENT CORP.FREEJAY INDUSTRIES INC.LE FRONT DES TRAVAILLEURS UNIS DE SEPT-ILLS INC.FRONTENAC MAINTENANCE INC.THE FRUIT CART LTD.FRANK FURTADO INC.UMBERTO FUSCO ENTERPRISE LTD.FUTURA CORPORATION.FUTURE FURNITURE INC.G.G.RENOVATION & CONSTRUCTION (HENRI BOURASSA) INC.G.R.BRICK & STONE WORK LTD.GAGE PRESS LIMITED.GAGNIER, FLEURY & ASSOCIES INC.GAGNON ET GELINAS INC.GAGNON & TREMBLAY LTEE.CALA RTS INTERNATIONAL LTD.GALERIE DE LA MASCOTTE LTEE.LES GALERIES DU BOULEVARD INC.LES GALERIES GRAND-PORTAGE INC.Touraine.Montréal.Montreal.Montreal.Boucherville New Carlisle St-François.Malartic.Montreal Montréal.Ste-Foy.Montréal.Montréal.Montréal.Montreal La Providence Montreal Montreal.Sept-Ile«.Montreal.Montreal.Montreal.Gatineau.Montreal.Montreal .Montréal.Ste-Rose-Est St-Jean.Montréal.Rouyn.Beloeil .Montreal.Montréal.Mont-Laurier.Riviére-du-Loup.1971 à/to 1973 incl.1971 et/and 1973 1967 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1971 à.'to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1972.1973 1967 à/to 1973 incl.1962 à/to 1964 incl.1966.1968 à/to 1973 incl.1967.1971 à/to 1973 incl.1971 à/1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1972.1973 1967, 1969.1972, 1973 1971 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1966.1968 à/to 1973 incl.1962.1963.1965, 1970 à/to 1973 incl.1962 à/to 1973 incl.1972.1973 1967 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1972.1973 1964 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1972, 1973 1972, 1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n\" U 6377 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed J.GAMELIN INC.GARAGE FORTIN INC.GARAGE GAGNE LTEE.GARAGE MARCEL CASTONGUAY INC.GARAGE MAURICE & RICHARD INC.GARAGE SEVILLE LTEE.GARAGE UNIVERSEL PIAZZA INC.GARAGE VIADUC LTEE.GARAGE ZEMBRI LTEE.GARDENIA CLEANERS AND SHIRT LAUNDRY CO.LTD.PHILIPPE GARIEPY INC.HENRI GARNEAU INC.GARON AUTOMOBILES INC.G ATI EN ELECTRIQUE INC.GENERAL FOUNDRY CO.LTD.GESTION FLAMBEAU INC.JACK GOODIS ENTERPRISES INC.LE GOURMET FINE FOODS INC.GOURMET FOOD PRODUCTS LTD.GREAT SCOTT REALTY CO.LTD.GRUE MOBILE SAGUENAY LTEE.PAUL-EMILE GUAY INC.H.G.MANAGEMENT ENTERPRISES LTD.LES HABITATIONS FUTURA INC.HALT-BOREN INVESTMENT CORPORATION HEAD FOOD CORPORATION.HEBREW FRIENDSHIP GROUP INC.BRIAN HIGGINS & ASSOCIATES INC.HOTEL LA GUADELOUPE INC.LES HOTESSES DE RIGAUD INC.ICE CREAM INN LTD.IMCO ENTERPRISE LTD.LES IMMEUBLES B.P.R.INC.LES IMMEUBLES BOURDEAU INC.Ste-Anne-de-Sorel.1968 A/to 1973 incl.Shawinigan.1966, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1966,1967, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1965,1966,1967,1969 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1972,1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.St-Léonard.1972, 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Sulpice.1971 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1965 à/to 196S incl., 1971 à/to 1973 incl.Lachute.1966 à/to 1968 incl., 1P70 à/to 1973 incl.St-Michel.1968 à/to 1973 incl.Windsor.1966, 1968 à/to 1973 incl.Trols-Rivieres.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1961 incl.1969 à/to 1973 incl.Chicoutiml.1972,1973 Québec.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl, Montreal.1957,1960, 1066 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.,.1971 à/to 1973 incl.Morin-Heiahts.1969 à/to 1973 incl.Rigaud.1965 à/to 1973 incl.Longueuil.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Québec.,,.19§9 à/to 1973 incl.Québec.1969 à/to 1971 incl., 1973 lY.il S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 3.1973.Vol.105.No.U Nom de la compagnie Name of the company IMMEUBLES BRUYERE INC.LES IMMEUBLES GASTON INC.LES IMMEUBLES JACQUES-CARTIER INC.LES IMMEUBLES MANSEAU INC.LES IMMEUBLES TRIMAUR INC.LES IMPORTATIONS S.A.N.INC.LES INDUSTRIES CADY LTEE.LES INDUSTRIES LUCERNE LTEE.LES INDUSTRIES DE MACHINERIE LTEE.LES INDUSTRIES VALCARTIER INC.INTER FLORA QUEBEC CORPORATION.INTERNATIONAL REINSURANCE BROKERAGE LTD.ITALIEN EXPRESS TRAVEL SERVICE LIMITED.JAVELIN ENTERPRISES LTD.LA JEUNE CHAMBRE DE CAUSAPSCAL INC.EUGENE JOBIN INC.JONVER ENTERPRISES INC.KASSIN BROS INC.KENEC CONSTRUCTION LIMITEE.KERN'S FUR LTD.KEY DATA SERVICES INC.KOLSON ENTERPRISES INC.KOTAI MUSIC INC.L.L.PROMOTIONS LTD.L.4 L.REALTIES INC.L.M.AUTOMOBILE INC.L.M.M.INC.L.4 P.MAINTENANCE CLEANERS INC.LA PRAIRIE AIRCRAFT INC.LA SALLE TIRE CASING LTD.LABORATOIRE METROPOLITAIN D'ELECTROENCEPHA-LOGRAPHIE LTEE.LABORATOIRE DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ET MEDICAMENTS BREVETES INC.LACHINE FRUIT INC.LAKEFIELD CORPORATION.LAKEVIEW ENTERPRISES INC.FRED A.LALLEMAND CONSTRUCTION LTEE.LAMEX INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1965 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1972, 1973 Québec.1965 à/to 1973 incl.Joliette.1969, 1971 à/to 1973 incl.Trois-Rivicres.1964, 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1971, 1973 St-Georges.1967, 1973 Montréal.1965 à/to 1973 incl.Longueuil.1969 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1965, 1972.1973 Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Causapscal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Sillery.1972.1973 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Dorion.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Dorval.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Salaberry-de-Valleyfield.1967 à/to 1973 incl.Victoriaville.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Laprairie.1968 à/to 1973 incl.LaSalle.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1970 à/to 1973 incl.Amos.1971 à/to 1973 incl.Lachine.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Laurent.1966, 1968 à/to 1973 incl.Richelieu.1966 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année.n° U 6379 Nom de la compagnie Same of the company LANGELIER BOULEVARD DEVELOPMENT CORP.LAVE-AUTO STE-FOV LTEE.GAETAN LECLAIR INC.LEIBO SALES CO.LTD.LEISURE PRODUCTS INC.LEMAY TEXTILES LTEE.L.W.LEMELIN INC.LERCH ENTERPRISES LTD.LIBRAIRIE MAISONNEUVE INC.LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE LA PAROISSE DE ST-EUSTACHE INC.LIQUEURS ST-GEORGES LIMITEE.THE LITTLE ONES' CAR CLUB INC.LOCAL METAL & WASTE LTD.LOCATION GARANTIE LIMITEE.LOCO TRANSPORT INC.LOGRUME LTD.LES LOISIRS LA MINERVE.LOLA PRINTING INC.LONGUE-POINTE CONSTRUCTION INC.LORCO LIMITEE.LORD AUTO PARTS LTD.LORNE ELECTRIC (QUEBEC) LTD.LOUCAM CO.LTD.LUCERNE FINANCE CORPORATION LIMITED.LULU-ANN INC.LUMINEX INC.PAUL LUSSIER LTEE.LYONS ENTERPRISES (QUEBEC) CORP.M.& L.HOLDINGS INC .M.P.T.INVESTMENTS LTD.M.A R.DEVELOPMENT INC.MADONNA NOVELTIES CO.LTD.MAHARANI RESTAURANT LTD.LA MAIN FRATERNELLE DE QUEBEC INC.LA MAISON DU CAMPEUR INC.LA MAISON MEXICAINE (LA CASA MEXICANA) LTEE.Adresse Rapports non produits Addret» Return! not filed Montreal.1965.1968 à'to 1973 incl.Ste-Foy.1967, 1969 1/to 1973 incl.Iberville.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Westmount.1971 à/to 1973 incl.Ste-Croix.1970 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1971 à/to 1973 incl.Dorval .1968 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.St-Eustache.1964.1968 à/to 1973 incl.St-Georges.1959, 1968, 1973 Longueuil.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1906 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Anjou.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.La Minerve.1972.1973 Montreal.1971 à/to 1973 Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1959.1964.à/lo 1967 incl., 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1970 à,to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Québec.1967 à/to 1973 incl.Kénogami .1965 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Québec.1964 à/to 1973 incl.Charlesboun.1964 à/to 1973 incl.8te-Foy.1965 à/to 1973 incl. 6380 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973.Vol 105, No.U Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed MAJESTIC ELECTRIC QUEBEC LTD.LES MAJORETTES ETOILES DE FORESTVILLE INC.MALTA ITALIAN RESTAURANT INC.MANTAB TRADING CORPORATION.MAPONET INC.MARANET INVESTMENT CORP.MARC SHOES JOBBERS INC.LE MARCHEUR DE VALLEYFIELD INC.MARCOLAND MINES LTD.MARLENE FASHION SHOPS INC.MARSHALL ELLIS LIMITED.MARTIN BROTHERS INC.FRANCE MAT CONSTRUCTION LTD.MAT-O-MATIC INC.MAULTON HOLDINGS (QUEBEC) LTD.MAUZONE (FOOD) CATERERS LTD.MEDITERRANEAN FISHERIES LTD.MEGATION CORPORATION LTD.METRO CATERING SERVICE INC.METROPOLITAN MORTGAGE BROKERS LTD.MILROT INVESTMENTS LIMITED.MISS DE MAISON NEUVE INC.MODERN PAINTING CONTRACTORS INC.____ MONT GALE SKI CENTRE LIMITED.Montreal.Forestville.Montreal.Montreal.Laval.Montreal.Montreal.Salaberry-de-Valleyfield.Montreal.Montreal.Montreal.Magog MONTCLAIR AUTOMOBILES LTEE.MONTE CARLO UNIFORMS INC.MONTE CASINO SOCIAL CLUB INC Montreal.Mataganii.Montreal.Montreal.Montreal.Hull.St-Laurent.Montreal.Montreal.Montreal.Chomedey.St-Bruno.de-Montarville St-Féliclen.Montreal.St-Calixte THE MONTREAL FREE SCHOOL INCORPORATED.MONTREAL .HAIR n COMPANY LTD.MONTREAL OIL CARRIERS INC.MONTREAL P A: L AUTO LTEE.MOONSTAR INC.MORAV HOLDING CORP.Montreal,.E.MORIN & FILS INC.,.Sherbrooke L.P.MORIN ET ASSOCIES INC.Montréal.Montreal.Montreal.St-Laurent.Montréal.Montreal.1968 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1966.1971 à/to 1973 incl.1967.1969 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1948, 1960 à/to 1963 incl., 1965, 1967, 1969, 1971 à/to 1973 incl.1962 à/to 1964 incl., 1966 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1972, 1973 ii)69 à/to 1973 incl.1962.1971 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1967, 1971 à/to 1973 inol.1967 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1972.1973 1965 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1957, 1960 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 Incl.1960, 1967, 1969 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 Incl.1971 à/to 1973 incl.1964, 1973 1968 à/to 1973 incl.1964, 1967 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 Inol.1970 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\tî novembre 1973, 105e\tannée, »° U 6381 Nom do la compagnie\tAdresse\tRapports non produits Name of the company\tAddress\tReturns not filed \t\\Tnn t rpiil\t1969 à/to 1973 incl.\tMont-Royal.\t.1965, 1969 à/to 1973 incl MORT ROSS PRODUCTIONS INC.\t\t1972.1973.MOSAIC CORPORATION OF NORTH AMERICA LTD\tMontreal.\t1965 à/to 1973 incl.MOTEL MOULIN ROUGE INC.\tTrois-Riviùres.\t.1969 à/to 1971 incl., 1973 \t\t MOTIVEX LTEE.\t\t.1970 à/to 1973 incl.\t\t MOTOR HOME RENTAL INC.\t\t.1972, 1973 MOUNTAIN PRESS LTD.\t\t.1964 à/to 1973 incl.MOUNTCREST CONSTRUCTION INC.\t\t \tMontréal.\t1971 à/to 1973 incl.MOZART (SHERBROOKE) LIMITED.\tSherbrooke.\t.1971 à/to 1973 incl.\tSt-Michel.\t.1965 à/to 1973 incl.\t\t.1965 à/to 1973 incl.NETTOYEURS WRIGHTVILLE INC.\tHull.\t.1971, 1973 \t\t.1965 à/to 1973 incl.NEW FORM FURNITURE LTD.\t\t.1970 à/to 1973 incl.NICOMAR PUBLICITE INC.\t\t.1971 à/to 1973 incl.\tMontreal.\t.1960 à/to 1973 incl.NORMAR HOLDINGS LTD.\t\t1969 à/to 1973 incl.\tMontreal.\t, .1970, 1972, 1973 NORTH END JEWISH BUSINESS MEN'S CENTER INC.\t\t1957.1958, 1962.1963.\t\t1971 à/to 1973 incl.NORTH WEST MOTOR SALES LTD.\t\t1965 à/to 1973 incl.\t\t1971 à/to 1973 incl.\t\t.1972, 1973 NU'WAY INVESTMENTS CORPORATION LTD.\t\t1962 à/to 1973 incl.\t\t.1971 à/to 1973 incl.L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE\tLac Etchemin\t1969.1972,1973 L'ETCHEMIN\t\t L'ORGANISATION DES TERRAINS DE JEUX DE\tGagnon.\t1962 à/to 1965 incl.GAGNON INC.\t\t1973 \t\t.1966 à/to 1973 incl.\tSte-Foy.\t.1961, 1964 à/to 1973 incl.\t\t, , 1967, 1969 à/to 1973 \t\tincl.\t\t1970 à/to 1973 incl.\t\t.1963, 1968 à/to 1973 incl.PANLACONIAN ASSOCIATION OF MONTREAL INC.\t\t.1966 à/to 1973 incl. (Ï3S2 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, November 3, 1073, Vol.105.No.U N'ont de la compagnie iVnmc nfthe comjtttn>t A.lrc.c Address Rapport! non produits Returns not filed PAPINEAU FLORIST INC.PARALLEL PETROLEUM LTD.PARC: FLOORING LIMITED.PARK VIEW REALTIES BROKERS LTD PATISSERIE LURIC INC.PAVILLON ST FRANÇOIS INC.PERMA-HSTIIE INC.LES PETROLES BRASSARD LTEE .PETROLEUM BUSINESS SERVICES LTD.PEVEE MOUNTAIN DEVELOPMENT CORPORATION PINE HILL SAND AND GRAVEL INC.PLACE LONGUEUIL INC.LES PLACEMENTS BRO-LONG LTEE.LES PLACEMENTS BULL INC.PLACEMENTS DEKA INVESTMENTS INC.Monlreal.1958, 1962 1964 ft/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Alma.1966 a/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Caiwle-Ia-Madeleine .1971 A/to 1973 incl.Drumniondville.1970 A/to 1973 incl.Montreal.1964.1965, 1966.1970 A/to 1973 incl.Hoherval .1970 à/to 1973 incl.West mount.1972.1973 Montreal.1972, 1973 Montreal .1968 à/to 1973 incl.LonKueuil .1971 à/to 1973 incl.Montréal .197C, à/to 1073 incl.Sherbrooke.1972, 1973 Montréal.1964.1965.I960 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Sherbrooke .1967 à/to 1973 incl.Lachine.1970 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1968 à/to 1973 incl.LES PLACEMENTS FRANCO-AMERICAINS LTEE.PLACEMENTS HIBOU INC.LES PLACEMENTS LOMAT INC.LES PLACEMENTS LOUISE INC'.LES PLACEMENTS LUCIANNE INC.\".Sherbrooke.1970 à/to 1973 incl.LES PLACEMENTS QUIRION INC.Loretteville.1966 A/1973 incl.POISSONS FRAIS DE LA GASPESIE INC.Laval.1970 à/to 1973 incl.PONDEROSA FOODS LTD.Montreal.1966 à/to 1973 incl.POULIN & CATELLIER INC*.CharlesbourR.1970 à/to 1973 incl.PRIPSTEIN'S CAMP INC.Montreal.1971 à/to 1973 incl.PRODUCTIONS FONTAINE INC.Montréal.1970 à/to 1973 incl.LES PRODUCTIONS GASTON LAPIERRE INC.Montréal.1972, 1973 LES PRODUITS EN BOIS LEPAGE INC.Ste-Anne-des-Plaines .1963 à/to 1966 incl.1970 à/to 1973 incl.PRODUITS FORESTIERS LATHER INC.Templeton.1972, 1973 LES PRODUITS MOONGLOW CIE LTEE.Bouchcrville.1966.1970 à/to 1973 incl.LES PRODUITS TUR-MO INC.Venise-en-Québec.1968 à/to 1973 incl.PROVINCIAL CATERING LIMITED.Aima.1963 à/to 1973 incl.PROVINCIAL FLEET LEASING LTD.Montreal.1954.1969 à/to 1973 incl.PROVINCIALE FORME LTEE.St-Janvier.1968 à/to 1973 incl.PUBLICATIONS LE MONDE DE STE-FOY INC.Ste-Foy.1968 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973.105' année, n° U 6383 Nom de la compagnie Name of the company QUALITY BUILDING MAINTENANCE LTD.QUEBEC FRAGRANCES CORP.QUEEN'S GARAGE LTD.M.QUINTAL INC.R.B.CONSTRUCTION INC.R.C.FRANCHISE BROKER LTD.R.D.DESIGN & SEAL INC.R.P.B.CONSTRUCTION LTEE.RADIO CAPLAN INC.RENAUD & FRERES INC.RENEE CARPET LTD.RESTAURANT LE BOUVILLON GRILLE INC.RESTAURANT DAUVIL INC.RESTAURANT DE FRANCE INC.RESTAURANTS LE BUCHERON INC.RIENDEAU & GASCON INC.MARC ROBERT LIMITEE.RON MORTGAGE & INVESTMENT CORP.RONA-FROH LTD.ROUSSEAU (STE-FOY\") INC.GASTON ROY SHELL SERVICE INC.MARCEL ROY & ASSOCIES INC.ROY'-LOU ENTERPRISES LTD.S.F.MACHINERY LTD.S.F.TRANSPORT INC.S.S.GALA NAVIGATION INC.ST.JAMES GOLD MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).ST.LAURENT SPORT INC.LE SAINT-FRANÇOIS PEE WEE DE SHERBROOKE INC.LES SAGUENEENS SENIOR INC.SALAISON DE BOURGET INC.J.F.SARRASIN INC.SAVERS FRANCHISE CORP.ROSARIO SCALIA CONSTRUCTION LTEE.SECRETARIAL TRAINING CENTRE LTD.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1969 à/to 1973 incl.St-Pierre.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à.'to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Charlcsbourg.1964 à/to 1973 incl.Sillery.1971 à/to 1973 incl.St-Jean-Chrysostome.1971 à/to 1973 incl.Dorval.1968 à/to 1973 incl.Sept-Iles.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1935.1946, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1972, 1973.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1972.1973.Beauharnois.1965 à/to 1973 incl.Beauport.1966, 1969.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1959, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1972, 1973.Ste-Thérîse.1968.1970 à/to 1973 incl Laval.1969.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.St-Rémi.1972, 1973.Laval.1972.1973.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1937 à/to 1973, Montreal.1971 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1965 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1966 à/to 1973 incl.Joliette.1963, 1965 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1965, 1967.1971 à/to 1973 incl.St-Laurent.1973. 6384 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Nom de la compagnie Name of the company SEE EUROPE TOURS INC.SERVICE DE CADRES HOSPITALIERS INC.SERVICE DES LOISIRS ST-EUSEBE DE MONTREAL.SGA MOTEL LTD.SHERRICK MOTORS LTD.SIGI MOTORS (MONTREAL) LTD.SILVER DOLLAR CABARET INC.LEONARD SILVER KURS INC.PRANK SITAR INC.SIXTY-FIVE DEVELOPMENT LTD.SNOW FIRE INDUSTRIES LTD.SOCIETE CULTURELLE DE SEPT-ILES INC.SOCIETE DE FORMULES MECANOGRAPHIQUES INC.SOCIETE FORTEX INC.SOCIETE FUNERAIRE ST-HYACINTHE INCORPOREE.LA SOCIETE VAL-BOURG INC.SOCIETE ZOOLOGIQUE DE MALARTIC INC.SOSNER'S Y.CAFETERIA LTD.SOUDURE SAGUENAY LTEE.SOUTH SHORE FLOORING INC.SPECTACLES SONORES DU CAP INC.SPRINGER SWISS EMBROIDERY WORKS INC.STANBRA MOTORS INC.STARDUST CABARET INC.STENROSE CORP.RAYMOND STEPHEN MORTGAGE & INVESTMENTS CORP.STUDIO DE SANTE L'OLYMPE INC.SUN WARE (LONGUEUIL) LIMITEE.SUPER MAINTENANCE (S.M.) LTD.SWAN HUMIDIFIER CO.LTD.SYNDICATED BUSINESS BROKERS INC.T.F.RECREATIONS INC.T.M.PAYSAGISTES INC.TAVERNE EMPIRE LTEE.TAVERNE L.& M.INC.THE TECUMSEH GOLF AND CURLING CLUB.Adresse Address Rapport non produits Returns not filed Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1972.1973.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Candiac.1969 à/to 1973 incl.Anjou.1965 à/to 1973 incl.St-Georges.1971 à/to 1973 incl.Sept-Iles.1969.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972.1973.Montréal.1969 à/to 1973 incl.St-Hyacinthe.1965 à/to 1973 incl.Québec.1907 à/to 1973 incl.Malartic.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1967.1969 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1972.1973.St-Bruno-de-Montarville 1971 à/to 1973 incl.Sillery.1967.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970, 1971, 1973.Rosemcre.1964 à/to 1973 incl.Lachine.1962 à/to 1968 incl.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/ 1973 incl.Pointe-Claire.1971 à/U> 1973 incl.Longueuil.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969.1970.1973 Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Laval.1967 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Gatineau.1972.1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n° U 6385 Nom de la compagnie Name of the company TEENA CAPRICE GARMENTS INC.THEATRE POUR ENFANTS DE QUEBEC INC.TIRE CASING SUPPLY LTD.MARCEL TOUCHETTE & ASS.INC.TRACY FLEURISTE INC.TRAINING SYSTEMS FOR BUSINESS LTD.TRANSPORTATION BROKERS INC.GAETAN TREMBLAY ET ASSOCIES ASSURANCES LTEE.TROTTIER, O'BREADY 4 ASSOCIES INC.LA TROUPE FOLKLORIQUE « LES PIROUYS » INC.LA TROUPE SCOUTE ST-LOUIS DE MARIE DE MONFORT TWINS MORTGAGE 4 INVESTMENTS CORP.UNITED FILM ENTERPRISES LTD.UNITED TOUCH FOOTBALL ASSOCIATION OF MONTREAL .UNIVERSAL BOOKKEEPING AND TRANSLATION SERVICES INC.GAETAN USEREAU LTEE.V.S.M.AUTO PARTS CO.LTD.V.& V.4 B.CONSTRUCTION LTD.VACHON BUS SALES 4 MANUFACTURING LIMITED.VANGUY LTEE.LES VETEMENTS ELZEAR FORTIER LTEE.VIDA WELDING INC.VIENNA MOTEL INC.LE VIEUX POSTE INC.GERARD VIGEANT AUTOMOBILES INC.VILLA GAGNON INC.LES VILLAS LAURENTIDES INC.VILLAS DES PINS LTEE.VILLE EMARD SPORT INC.WALCO MOTELS LTD.WEBRO TOOL 4 MOULD MFG.LTD.WEST END ORNAMENTAL INC.WEST SIDE BOWL INC.W.M.WILKINS INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1970 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1968 à/to 1973 Boucherville.1972,1973 St-Joseph-de-Sorel.I960 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1964 à/to 1973 incl.Boucherville.1966 à/to 1973 incl.Alma.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1959.1960.1964 a/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Pierrefonds.1972, 1973 Montreal.1970 a/to 1973 incl.St-Michel.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1968 à/to 1973 incl.Levis.1964, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Québec.1969 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.St-Jean.1967.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.St-Luc.1970 à/to 1973 incl.Thetford-Mines.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Laval.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Côte St-Luc.1969 à/to 1973 incl.Châteauguay.1971 à/to 1973 incl. 63S6 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105.No.U Nom de la compagnie Name of the company A'lrr m- Address Rapports non produits Returns not filed WINDSOR BOWLING STABLES INC.ZAHAV INVESTMENT CORPORATION Montreal.1907.1970, 1972 et/and 1973 Montreal.1964 à.'to 1973 incl.54295-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.lettres patentes annulées Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4.5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont annulées à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle de ce deuxième avis.54295-0 Pierre Desjardinb.Director of the Companies Service.Letters Patent Annulled The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 4.5a and following of the Companies Information Act.the companies whose names follow are cancelled from the date of the publication in the Official Gazette of this second notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date A.4 D.TRANSPORT LTEE.A.L.D.L.DISTRIBUTEURS LTEE.A.P.G.ENTERPRISES LTD.A.S.S.F.INC.ADMINISTRADIM INC.AGENCES BALY ASSURANCES INC.AHUNTSIC CONSTRUCTION LTEE.ALARME DE SURETE (MONTREAL) INC.ANGLO-FRENCH INVESTMENTS (1966) CORPORATION____ ANOKI FISH AND GAME CLUB.AQUAMEX INC.AQUARIUS CLEANERS LTD.ARTEMIS SPORTSWEAR LTD.L'ASSOCIATION DES CITOYENS DE LA MAURICIE.ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE LA DAN8E DU QUEBEC ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS PETROLIERS DU QUEBEC INC.ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE ST-LOUIS DE TERREBONNE INC.L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA VILLE DE LEBEL-SUR-QUEVILLON ASSOCIATION QUEBEC-FRANCE DES JEUNES JURISTES ASTRA SERVICES TECHNIQUES INC.ATELIER DE FORMATION D'ANIMATEUR CULTUREL.ATLANTIC OIL PRODUCTS LIMITED.AUBERGE DU CHEVAL BLANC INC.Montréal.11 09 1967 St-Michel.26 03 1968 Sherbrooke.23 11 1955 Montreal.07 06 1971 Québec.24 11 1971 Montreal.31 12 1958 Montréal.21 04 1954 Montréal.16 12 1968 Montreal.29 05 1958 Hull.01 02 1921 Montreal.11 11 1969 Montreal.30 09 1970 Montreal.02 01 1970 Trois-Riviéres.10 08 1967 Pointe-Claire.28 03 1968 Montréal.16 09 1971 St-Louis de Terrebonne.28 10 1969 Lebel-sur-Quevillon.06 08 1969 Montréal.18 10 1968 Montréal.22 01 1068 Montréal.30 04 1970 Montreal.06 03 1967 Québec.11 04 1968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n\" U 6387 Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company\tAddress\t\tDate\t AUBERGE DES GREVES INC.\t\t15\t05\t1SÔ4 \t\t\t12\t1971 \t\t\t04\t1960 AUNIS INC.\t\t\t08\t1971 AUTOMATION DE QUALITE DE MONTREAL INC.\t\t05\t02\t1969 AUTO PORT INC____\t\t10\t09\t1964 AYLMER ROD & GUN CLUB INC.\t\t18\t04\t1961 BEAUCHESNES CLUB.\tLouiseville.\t00\tos\t1926 P.& N.BEAUDOIN CONSTRUCTION INC.\t\t.02\t06\t1972 BEAVER MINING CORPORATION.\t\t27\t10\t1971 BEAVER OIL CO.LIMITED.\t\t28\t01\t1954 \t\t\t10\t1970 \t\t\t12\t1971 ZENON BELLEROSE INC.\t\t06\t06\t1946 BELL-KAY INVESTMENTS INC\t\t\t] i\t1971 BELVICAR LTEE.\t\t16\t12\t1971 ARMAND BIBEAU CONSTRUCTION INC.\t\t19\t08\t1970 \t\t02\t01!\t1961 \t\t24\t02\t1966 E.BONETTI ET F.TENAGLIA MONUMENTS INC.\t\t29\t10\t1964 GABRIEL BOURASSA INC.\tVal d'Or.\t.26\t05\t1972 BOUTIQUE DU CADEAU NORSKE.INCORPOREE.\t\t04\t11\t1966 BRASSERIE DU CAPITAINE INC\t\t\t02\t1970 EDOUARD RRAIiLT INC\t\t04\t02\t1959 \t\t.16\t04\t1963 BRISSON (FOTTRRÎÎRFKï Ï.TKK\t\t02\t04\t1965 \t\t.28\t12\t1955 BRTTNF.T l\t03\t1968 08\t08\t1972 SI\t09\t1971 or,\t11\t1963 28\t11\t1966 20\t03\t1963 03\t04\t1963 20\t03\t1952 06\tos\t1958 15\t04\t1964 20\tM\t1968 16\tOl,\t1949 07\t11\t1968 28\t04\t1958 27\t09\t1962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1978, 106' année, n° M\t\t\t\t6389 Nom de la compagnie Home of the company\tAdresse Address\tIncorporation Date\t\t CLUB DE CHASSE DE LA DUNE INC.\t\t22\t06\t1967 CLUB DE CHASSE & PECHE CLEMENT INC.\t\t23\tM\t1955 CLUB CLATRO INC.\t\t23\t01\t1959 CLUB CLERION INC.\t\t28\t07\t1959 CLUB CONCORDE.\tMontréal.\t24\t11\t1964 CLUB DU CRAN INC.\t\t28\t06\t1964 \t\t22\t07\t1952 CLUB DANSEREAU INC.\t\t25\t07\t1961 \t\t12\t01\t1962 \t\t11\t04\t1962 \t\t21\t04\t1947 \t\t24\t06\t1966 \t\t23\t02\t1953 \t\t03\t12\t1959 \t\t19\t12\t1956 CT.TTR mi FAUCON D'OR INC\t\t17\t02\t1969 \t\t05\t01\t1965 fîT.TTR nFS fiASPAHnS INC\t\t15\t02\t1960 \t.St-Jérôme.\t10\tOS\t1964 pi i h tîf r.niF nF YfURncïCHVii.iiFj INC\t\t26\t08\t1970 \t\t23\t07\t1948 \t\t12\t08\t1949 \t.Baie St-Paul.\t17\t06\t1967 \t\t26\tM\t1963 \t\t03\t06\t1961 \t\t12\t01\t1954 \u2022PI itr rtTVFMIT f Tï V I AVAT.OIIF.ST\t\t14\t01\t1955 \t\t16\tO.i\t1960 \t\t03\t08\t1959 \t\t07\tor,\t1955 \t\t29\t01\t1932 \t\t01\t00\t1956 \t\t11\t12\t1964 \t\t09\t00\t1938 \t\t03\t06\t1961 \t\t28\t02\t1967 \t\t\t04\t1962 6390 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.M Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name ol the company Addrct) Date LE CLUB OPTIMISTE DE ST-HYACINTHE INC.\t\t\t0.1\t1969 CLUB DE PECHE ET CHASSE DU LAC LAUREL INC.\t\t02\t02\t1960 \t\t\t1 !\t1970 \t\t\t08\t1955 \t\t\t04\t1961 CLUB DE PROTECTION DE LA FAUNE DU LAC\t\t.19\t01\t1967 MASSON INC.\t\t\t\t CLUB DES QUILLEURS DU QUEBEC (1962) INC.\tQuébec .\t.22\t10\t1962 LE CLUB DE SECURITE DU TRANSPORT ECOLIER INC.\t\t\t04\t1972 LES CLUBS DE FRANCS.INCORPOREE.\t\t\t07\t1952 \t\t.17\tcil\t1947 COLISEUM DIVERSIFIED HOLDINGS INC.\t\t\t01\t1971 COMMERCIAL LITHO PLATE GRAINING LTD.\t\t.12\t11\t1954 \t\t23\t03\t1967 CONSEIL ECONOMIQUE RURAL DE LA REGION 3.\t\t\t07\t1969 CONSTRUCTION BEFOK LTEE\t\t,,.18\t10\t1971 CONSUMERS PRINTING SUPPLIES LTD.\t\t.01\toc,\t1970 COSEC CONSTRUCTION INC.\t\t.01\tm,\t1961 COSMETRIX INC.\t\t01\t08\t1971 PATRICK COTE INC.\tCharlesbourg.\t28\t02\t1972 COTE ST-LUC CAR WASH INC.\t\t.19\tm\t1962 COURTEMANCHE EQUIPEMENT INC.\t\t29\t03\t1961 CREATION DE MODE ECUSSON INC\t\t.13\t03\t1972 DAIRY BARN' STORES OF CANADA LIMITED.\t\t\t08\t1971 DECIN INVESTMENTS INC.\t\t.02\t08\t1961 DENTO INC.\t\t30\t09\t1971 LES DEVELOPPEMENTS DES BEAUX QUARTIERS LTEE .\tMontréal.\t20\t01\t1967 DISTRIBUTEURS MONTMORENCY LIMITEE.\t\t\t08\t1960 DISTRIBUTION CAPITALE LTEE.\t\t.11\t01\t1968 LES DISTRIBUTIONS MINI-MAXI (JULIETTE) INC.\t\t\t02\t1971 \tSherbrooke.\t.21\t01\t1953 \t\t.24\t09\t1971 DOMAINE MON PLAISIR INC:.\t\t10\t08\t1958 \t\t03\t11\t1971 \t\t.08\tcm\t1970 \t\t07\t(IN\t1959 DUNTON INVESTMENTS LTD.\t\t.02\t08\t1959 ANDRE DURIVAGE LAMARRE PRODUCTIONS INC.\t\t07\t03\t1972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n° U 6391 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date E.& M.PROMOTION SALES LTD.EBENISTERIE AMI INC.ECONOMIE SOCIALE LTEE.EDIFICO INC.LES EDITIONS L'ACTION INC.LES EDITIONS MUSICALES BARMA INC.EDITIONS SITUATION INC.LES EDITIONS SOLUTIONS LTEE.EFLOL INC.EGECO LTEE.ELECTROSOL INC.ENTREPRISES BEAUBIEN INC.LES ENTREPRISES BUARD INC.LES ENTREPRISES DE FOY INC.LES ENTREPRISES DIMCO LTEE.LES ENTREPRISES J.M.INC.LES ENTREPRISES POINTE VALAINE LTEE.LES ENTREPRISES ROLAND DAIGLE INC.ENTREPRISES ST-ADOLPHE INC.ESQUIRE REALTY CORP.EUROPE PLASTIC MOULDS, TOOLS & DIES LTD.EXETER INVESTMENTS LTD.FEDERAL PLASTICS LTD.FEDERATION HALTEROPHILE DU QUEBEC.FERCO PAINTS & MACHINERY RENTALS LTD.FINDEC INVESTMENTS INC.FLASH SCREEN PROCESS INC.FOCAL INTERNATIONAL INC.J.M.E.FORTIN INC.FOURNITURES CHIRURGICALES DU QUEBEC LTEE.G.L.OPTICAL INDUSTRY INC.G.M.C.EXCAVATION INC.MARCEL A.GAGNON & ASSOCIES INC.GAI LOGIS INC.FERNAND GAUDREAU INC.A.GAUTHIER & FILS LTEE.GENERAL BUILDERS ASSOCIATION.Montreal.19 00 1970 Montréal.28 01 1969 Sherbrooke.12 03 1929 Laval.17 07 1967 St-Eustache.06 12 1961 Montréal.18 12 1967 Québec.26 10 1971 Montréal.18 10 1971 Montreal.22 10 1971 Montréal.16 09 1971 Québec.15 10 1971 Montréal.01 03 1957 Beauceville.10 12 1971 Québec.07 03 1958 Donnacona.02 11 1971 Québec.18 04 1683 Otterburn Park.28 05 1971 Orsainville.13 11 1970 St-Adolphe d'Howard.16 10 1966 Montreal.11 06 1959 Montreal.09 02 1968 Montreal.02 03 1959 Montreal.15 10 1971 Québec.02 06 1969 Montreal.29 01 1963 Montreal.02 03 1961 Montreal.15 02 1962 Montreal.10 10 1961 Montreal.20 01 1958 Montréal.08 10 1966 Montreal.10 08 1971 La Salle.18 11 1971 Montréal.19 12 1957 Québec.17 10 1963 Rouyn.25 03 1955 Yamachiche.16 01 1959 Montreal.27 02 1968 6392 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, Notember 3.1973, Vol.105.No.U Nom de la compagnie Namt of the company Adresse Address Incorporation Date GIF BEC LTEE.GITA INTERNATIONAL INC.GOLD MEDAL DEVELOPMENTS INC.A.GOODI8 INC.J.A.GOSSELIN LTEE.GRANOW INCORPORATED.HAMPSTEAD GOLF CLUB INC.GUY HEBERT INC.HOTEL MOTEL TAPANEE INC.HOWARK CORP.LTD.HY FASHION MILLINERY INC.LES IMMEUBLES BEAUHARNOIS INC.IMMEUBLES DE LA GRAND ROUTE INC.IMMEUBLES IMPERIAL LTEE.IMPORTATIONS NARBONNE INC.LES IMPORTATIONS TARON INC.LES INDUSTRIES PELOQUIN LTEE.INTER-CITY COMMERCIAL INC.ISSBRO INVESTMENTS INC.JAFRA INC.JAYMAR CONSTRUCTION LTD.LA JEUNE CHAMBRE DE LA SARRE INC.JOLIETTE PLOMBERIE 4 CHAUFFAGE INC .KABIGX LTD .KIBA INC.ALEX KINDLER INC.KNOPP'S COIFFURE CO.ALDEX KRISHNA INC.LABELLE ASSOCIATES INC.LAVAL EMBELLISSEMENT LTEE.LIGUE DE BALLON SUR GLACE DE VTCTORIAYTLLE INC.LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE ST-EUSTACHE OUEST INC.Quebec.21 02 1972 Montreal.29 07 1969 Montreal.>» -» 1959 Montreal.W M 1958 St-Romuald d'Etchemin.II 04 1947 Montreal.29 10 1963 Oranby.25 02 1935 St-Samuel.15 02 1972 Ste-Anne-du-Lac.20 11 1969 Westmount.17 06 1958 Montreal.06 02 1963 Beauliarnoia.07 12 1971 Montreal.23 06 1964 Montréal.28 10 1953 Laval.29 00 1970 Ste-Foy .10 03 1971 Montréal.15 02 1972 Montreal.27 02 1959 Montreal.02 03 1961 St-Jérôme .05 12 1962 Montreal.30 09 1952 LaSarre.15 05 1962 Joliette.13 04 1959 Montreal.10 10 1962 Montreal.22 06 1970 Mont-Royal.18 02 1960 Montreal.14 03 1952 Montreal.23 10 1967 Montreal.28 05 1956 Montréal.29 04 1966 Victoriaville.28 10 1969 St-Eu-tache 1.i 1964 \t\t.36\t11\t1968 \t\t\t03\t1959 LITTLE SUE CREATIONS INC.\t\t.26\t05\t1971 LIVRO TRANSPORT INC.\t\t\t09\t1971 LOGIS (QUEBEC) INC.\t\t\t09\t1968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 10.5' année, n' H 6393 Nom de la compagnie Adresse Incorporation A*am« of Ihf company\tAâdrtH\t\tDate\t LOTISSEMENT QUEBEC LTEE.\t\t.03\t08\t1971 \t\t.21\t06\t1970 \t\t.25\t10\t1950 \t\t.09\t03\t1966 MACHINERIE ST-MAURICE INC.\t\t.27\t01\t1971 MACHINERIE TOI'SIONANT INC\tMontréal.\t.02\tm\t1970 LES MACHINERIES LEMA LTEK\t\t.20\t11\t1971 \t\t.28\t12\t1971 1 4 MAISON MADEMOISELLE DE PARIS LTEE\tMontréal.\t.29\t07\t1970 MAISONS MODULAIRES INC\t\t.29\t12\t1967 _ MANSF4.I\" MILLING LTD\t\t.27\t07\t1967 \tMont-Laurier.\t.13\t03\t1969 MAPI.F CT.FANTNO CENTER INC\t\t.00\t03\t1970 \t\t.19\t05\t1970 \t\t.30\t05\t1972 \t\t.30\t12\t1964 \t\t.03\t02\t1953 \t\t.06\t00\t1969 MFI7RT.FR RFI.T FHT'MFl'R LTEE\tVal d'Or.\t.04\t08\t1958 I FS MFiï'NIFRS SI'PRFMFS LIMITEE\t\t.18\t11\t1968 MILAUM INVESTMENTS INC\t\t.02\t03\t1961 \t\t\t00\t1970 I.FS MOOF-5 TRONAT T TNC\t\t.08\t11\t1971 MONT STF-ÀDFT.F.T.OTÏfîF.INC\t\t.31\t01\t1069 MONTAOF PRODT7CTIONS INC\t\t\t06\t1971 \t\t.30\t01\t1970 MONTREAL COMMERCIAL FOREIGN TRADE COMPANY LTD.\t\t\t04\t1969 Ml'VIPlPil MflRTP.ir.F CORPORATION I.TD\t\t\t08\t1961 VFSfïFP TNVFSTXtFNTS INC\t\t.02\t03\t1961 \t\t.22\t02\t1965 \t\t\t01\t1959 \t\t\t06\t1958 \t\t\t03\t1959 NORCRFV CONSTRUCTION I TD\t\t.03\t08\t1956 \t\t\tM\t1958 \t\t\t12\t1955 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE L'ASSOMPTION.\t\t\t08\t1958 6394 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.M__ Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company Address Date OLIVE ELECTRO DYNAMICS INC.Montréal.16 01 1970 OLYMPIA ALUMINUM MFG LTD.Montreal.11 08 1967 PA.R.TRANSPORT INC.Montréal.28 03 1972 P.-M.PACKERS LIMITED.Mingan.10 04 1972 P.S.I.MANUFACTURING LIMITED.Pointe-Claire.28 05 1971 PAPETERIE ST-LAURENT INC.Tracy.07 1963 O.PARADIS INC.Montmagny.15 06 1971 L.PATENAUDE AUTO CENTRE INC.Laval.H 05 1971 PERMA-ROC INC.Montréal.07 09 1971 PHOEBUS IMPORTS INC.Montreal.29 10 1969 LES PLACEMENTS LYON LTEE.Montréal.29 07 1966 LES PLACEMENTS TRACY INC.Sorel.26 06 1954 J A.POIRIER LIMITEE.Granby.20 01 1959 LES PONÇAGES INDUSTRIELS INC.Mont St-Hilaire.16 12 1971 POSTERITEX INC.Montreal.06 11 1970 PRATTE & COMPANY LIMITED.Quebec.28 09 1936 PRECISION STEEL RULE DIES LTD.Montreal.01 12 1961 PREVILLE ASSOCIATES INC.Montreal.28 05 1956 LES PRODUCTIONS DA SYLVA INC.Montreal.03 12 1970 LES PRODUCTIONS HYD INC.Montreal.26 05 1965 LES PRODUCTIONS MOJACK INC.Montréal.26 08 1970 LES PRODUITS LAITIERS INTER-PROVINCIAUX LTEE.Granby.12 04 1967 LES PRODUITS TINO INC.Montréal.30 12 1970 PROMOTIONS DE TRAVAIL DE MONTREAL LTEE.Montréal.01 02 1971 QUEBEC FORGED PRODUCTS LTD.Montreal.18 12 1967 QUEEN'S HOTEL (MONTREAL) LIMITED.Montreal.30 11 1964 R.P.M.GARAGE INC.Montreal.19 03 1962 R.Q.BUILDERS INC.Lasalle.08 05 1967 RASPBERRY MAHOGANY SHOPS INC.Laval.29 01 1971 REISLER & WEISBORD INC.Montreal.13 11 1958 RELA CONSTRUCTION CO.LTD.Montreal.04 11 1965 LE RESEAU ELECTRIQUE POTVIN LTEE.Montréal.22 01 1967 RESTAURANT LE CAMPEUR INC.Québec.23 03 1967 RESTAURANT LE FLORENCE INC.Montréal.13 11 1967 RESTAURANT LEHOUX INC.Thetford Mines.13 08 1971 RESTAURANT MAMBO INC.Québec.16 12 1965 RESTAURANT LE NOCTURNE INC.Trois-Rivières.07 07 1970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n' U 6395 Nom de la compagnie Kame of the company Adresse Incorporation Address Date St-Je.in.14 09 1955 Montreal.04 07 1962 Montreal.12 04 1950 Montreal.02 03 1961 Montreal.29 12 1965 Montreal.15 04 1971 Montréal.- 20 09 1906 Montreal.17 08 1969 Montreal.29 08 1957 Montreal.17 01 1947 Mont Laurier.14 04 1970 Montreal.11 00 1963 Montreal.22 10 1956 Montreal.28 08 1971 Montreal.29 04 1959 Québec.01 04 1971 Montreal.15 08 1969 Montreal.30 09 1960 Sherbrooke.02 03 1971 St-Eustache.22 12 1970 Montreal.25 09 1970 Magog.25 07 1960 Montréal.01 12 1961 Montréal.18 03 1971 Montréal.31 08 1965 Montréal.18 12 1970 Montreal.11 08 1971 Repentigny.17 10 1969 Sorel.29 04 1939 Montreal.26 05 1947 Montreal.04 12 1959 Montreal.21 11 1966 Montreal.26 04 1972 Montreal.02 03 1961 Trois-Rivicres.29 11 1971 Québec.07 11 1966 Montreal.18 12 1957 RICHELIEU WOODWORKING LTD.RIGAUD FONDERIE LTEE.ROBITAILLE ELECTRIC CORPORATION.ROFDUB INVESTMENTS INC.ROL-ART SALES CO.S.A.U.S.INC.ST LOUIS RANCHO INC.ST MARTIN DEVELOPMENT CORP.STE THERESE INVESTMENT CORP.SALEM EXPLORATION LIMITED.SALON PIERRE DAOUST INC.SCHARF PAINTING & DECORATING CONTRACTORS LTD.SCREEN PROCESS SALES CO.SEAGULL PRK CO.LTD.SEAWOOD INVESTMENT CORP.SECURIBEC INC.SERVICE ESCO LTEE.SERVOPARC INC.SHERBROOKE STEAK HOUSE INC.SIJAN CONSTRUCTION INC.SILCAN MINES LTD.SOCIETE DE CRIMINOLOGIE DU QUEBEC.LA SOCIETE G.B.R.INC.SOCIETE IMMOBILIERE L.L.G.INC.SOCIETE NUCLETRON INC.SOCIEX INC.SOCRATES SCHOOL BUS SERVICE LTD.SOLIBEC INC.LE SORELOIS LTEE.SOUTHERN HOLDINGS CORPORATION.SPRUCEWOOD FISH & GAME CLUB.THE STAMP MART INC.STANWOOD PRECISION CORP.STELAT INVESTMENTS INC.STUDIO D AMAIGRISSEMENT FORME MIRACLE DE TROIS-RIVIERES INC.STUDIO 437 INC.SUNNYSIDE PROPERTIES INC. 6396 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol- 105, No.U___ 54295-0 Le directeur du service dee compagnies, Pierre Desjardins.54295-0 Pierre De&jardiks, Director of the Companies Service.Nom de la compagnie Adresse lMorDP™tio\" Name of the company Address SUNSET SPORTSWEAR INC.Montreal.19 11 1971 SUSCON CORPORATION.Montreal.05 12 1968 SOUTHGATE GRAPHICS LTD.Brossard.08 05 1967 SYNDICAT DES CONSOMMATEURS DU GUIDE ITALIEN Montréal.26 10 1965 INC.T.& T.CLEANERS INC.Montreal.25 06 1969 TAPIS LONGUEUIL INC.Longueuil.29 03 1967 JEAN-MARC TARDIF INC.Ste-Foy.05 02 1971 TEMPLETON DEVELOPMENT CORPORATION.Montreal.01 08 1957 TERKO INVESTMENT CORP.Montreal.16 03 1959 TERRACE LACORDAIRE INC.Montréal.13 03 1962 THEATRE DES PRAIRIES.Joliette.24 02 1966 LE THEATRIX.Longueuil.16 11 1970 THERMO-PAN INC.Sept-Ues.23 07 1971 THRUWAY AUTO CENTRE INC.Montreal.28 01 1964 TRAPPER QUEBEC INC.Sherbrooke.14 04 1966 TWIN PINNACLE TOWERS CORP.Montreal.08 11 1971 TROY INVESTMENTS LTD.Montreal.16 10 1958 UNITY LAND & HOUSING LTD.Montreal.28 01 1956 UNIVERSAL CONCRETE SERVICES LTD.Westmount.10 12 1966 RAYMOND VENDETTE LTEE.Laval.20 10 1966 VILLE EMARD PACKAGING COMPANY LTD.Montreal.12 12 1968 X-L SCREW MFG.CO LTD.Montreal.23 11 1970 ANTOINE ZACHARIE LIMITEE.Sacré-Coeur-de-Jésus.04 04 1972 ZEGO LTD.Montreal.15 10 1971 A & G ZILLMANN INC.St-Michel.16 02 1963 ZLATA PRAHA CLUB INC.Montreal.07 08 1929 WESTMOUNT BUSINESS SERVICES INC.Montreal.01 03 1972 WILRICH REALTY CO.LTD.Dorval.09 01 1957 WORLDWIDE HOLIDAY CLUB INC.Dorval.27 06 1969 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1973, 105' année, n° U 6397 Commission des transports du Québec Québec Transport Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission (Règlement 2, a.2.24) : : proprio motu » 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) i 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées.i.membre siégeant seul.\u2022\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulations 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) (ieneral transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). 6398 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1973, Vol.105, No.U ii.au moins trois membres.\u2014¦ transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.* Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux «le la région.ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(c) Verification of permits.(d) Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.(e) * Special permits.* In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.I \u2014 Avis de la Commission - proprio motu » : I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Com La Commission donne avis qu'elle entend décider des affaires suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.mission: The Commission gives notice of its intention to render a decision in the following matters in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publication.Hole M-456 19749-V GERARD HARBEC TRANSPORT INC., 200 Nord rue Comeau.Karnham, P.Q.Rôle M-455 9409-V BELANGER & FRERES F.NRC.31 rue du Fort.8t-Roch l'Achigan.Comté de l'Assomption.Que.Role M-454 23410-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200 rue St-Jacques.Oiéme étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-453 118-DYL ACTON VALE TRANSPORT INC.364 Boul.Roxton, CP.218.Acton Vale, Cté Johnson, P.Q.Rôle M-452 13963-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200 rue St-Jacques, Oicme étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-451 22346-V PAQUETTE, PAQUETTE.PERREAULT & RIVET, 200 rue St-Jacques, Oième étage, Montréal 126.P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Gérard Harbec Transport Inc.avec sa requête datée le 14 septembre 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Bélanger A: Frères Enrg avec sa requête datée le 24 septembre 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.Alain Coutu (23410-V) avec sa requête datée le 31 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Simpson's Sears Ltd.avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Speedway Express Limited (RS-459) (13963-V) avec sa requête datée le 6 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dan» la cause de M.Guy Rcusseau (22346-V) avec sa requête datée le 11 septembre 1973.With regard to the security given in the case of Gérard Harbec Transport Inc.with its application dated September 14, 1973.With regard to the security given in the case of Bélanger & Frères Enrg.with its application dated September 24,1973.With regard to the security given in the case of Mr.Alain Coutu (23410-V) with his application dated August 31.1973.With regard to the security given in the case of Simpson's Sears Ltd.with its application dated August 28, 1973.With regard to the security given in the case of Speedway Express Limited (RS-459) (13963-V) with its application dated August 6, 1973.With regard to the security given in the case of Mr.Guy Rousseau (22346-V) with his application dated September 11.1973. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, rt° U 6399 Rôle M-450 23417-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200 rue St-Jacques, Oième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-449 23412-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200 rue St-Jacques, 9ième étage, Montréal.P.Q.Rôle M-448 18363-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200 rue St-Jacques, Oième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-447 12425-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200 rue St-Jacques.Oième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-446 12425-V PAQUETTE.PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200 rue St-Jacques, 9ième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-445 17491-V J.LEBOEUF CARTAGE INC., B.P.26, Valleyfield, P.Q.Rôle M-444 23292-V J.P.LAGANIERE, 8470.rue Clarke.Montréal, P.Q Rôle M-442 23427-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, 9ième étage.Montréal 126, P.Q.Rôle M-157 254-V ACTON VALE TRANSPORT INC., 364, Boul.Roxton, CP.218, Acton Vale, P.Q.Rôle M-458 8448-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, Oième étage, Montréal 126, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.John J.Rosseway (23417-V) avec sa requête datée le 5 septembre 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.Jean-Yves Riopel (23412-V) avec sa requête datée le 22 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Oil & Industry Suppliers Ltd.(18363-V) avec sa requête datée le 12 septembre 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Léo Tremblay Transport Inc.(12475-V) avec sa requête datée le 17 juillet 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Léo Tremblay Transport Inc.(12475-V) avec sa requête datée le 21 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de J.Leboeuf Cartage Inc.(1741-V) avec sa requête datée le 16 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.J.P.Laganière (23292-V) avec sa requête datée le 14 septembre 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Hélène Gross (23427-V) avec sa requête datée le 27 juillet 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Acton Vale Transport (254-V) avec sa requête datée le 27 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Glengarry Transport (Québec) Ltd.(8448-V) avec sa requête datée le 11 septembre 1973.With regard to the security given in the case of Mr.John J.Rosseway (23417-V) with his application dated September 5.1973.With regard to the security given in the case of Mr.Jean-Yves Riopel (23412-V) with his application dated August 22, 1973.With regard to the security given in the case of Oil & Industry Suppliers Ltd.(18363-V) with its application dated September 12.1973.With regard to the security given in the case of Léo Tremblay Transport Inc.(12475-V) with its application dated July 17.1973.With regard to the security given in the case of Léo Tremblay Transport Inc.(12475-V) with its application dated August 21, 1973.With regard to the security given in the case of J.Lehoeuf Cartage Inc.(1741-V) with its application dated August 16.1973.With regard to the security given in the case of Mr.J.P.Laganière (23292-V) with his application dated September 14.1973.With regard to the security given in the case of Hélène Gross (23427-V) with her application dated July 27.1973.With regard to the security given in the case of Acton Vale Transport (254-V) with its application dated August 27, 1973.With regard to the security given in the case of Glengarry Transport (Québec) Ltd.(8448-V) with its application dated September 11, 1973. 6400 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1973, Vol.105, No.U Rôle M-450 17404-V PAQUETTE.PAQUETTE.PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, Oième étage, Montréal 12G, P.Q.Rôle M-460 87-V-S-l PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, Oième étage.Montréal 126, P.Q.Rôle M-461 22430-V EQUIPEMENT ET CONSTRUCTION BROMONT, 80, rue Principale, Granby, P.Q.Rôle M-462 23437-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques.Oième étage.Montréal, P.Q.Rôle M-463 19517-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, Oième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-464 23409-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, Oième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-465 10201-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, 9ième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-466 23411-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques Oième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-471 104-V BOYD'S EXPRESS LTD., 5850, Montée de Liesse, Montréal, P.Q.Rôle M-472 23436-V PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, Oième étage, Montréal 126, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Gilles Robert Inc.(17404-V) avec sa requête datée le 12 septembre 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Finch & Sons Transport (87-V) avec sa requête datée le 5 septembre 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Equipement et Construction Bromont (22430-V) avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Matthew Francis Donovan (23437-V) avec sa requête datée le 11 juillet 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.Claude Daignault (19517-V) avec sa requête datée le 6 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.Serge Coutu (23409-V) avec sa requête datée le 29 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Container Express Inc.(10201-V) avec sa requêle datée le 1er août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.Réjean Champoux (23411-V) avec sa requête datée le 17 juillet 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Boyd's Express Ltd.(104-V) avec sa requête datée le 6 septembre 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.André Alix (23436-V) avec sa requête datée le 12 septembre 1973.With regard to the security given in the case of Gilles Robert Inc.(17404-V) with its application dated September 12.1973.With regard to the security given in the case of Finch & Sons Transport (87-V) with its application dated September 5, 1973.With regard to the security given in the case of Equipement et Const ruction Bromont (22430-V) with its application dated August 28.1973.With regard to the security given in the case of Matthew Francis Donovan (23437-V) with his application dated July 11.1973.With regard to the security given in the case of Mr.Claude Daignault (19517-V) with his application dated August 6.1973.With regard to the security given in the case of Mr.Serge Coutu (23409-V) with his application dated August 29.1973.With regard to the security given in the case of Container Express Inc.(10201-V) with its application dated August 1st, 1973.With regard to the security given in the case of Mr.Réjean Champoux (23411-V) with his application dated July 17.1973.With regard to the security given in the case of Boyd's Express Ltd.(104-V) with its application dated September 6, 1973.With regard to the security given in the case of Mr.André Alix (23436-V) with his application dated September 12, 1973. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105- année, n' U (',401 Rôle M-443 SS1-V-S-1 PAQUETTE.PAQUETTE.PERREAULT & RIVET.200.rue St-Jacques, 9ième étage, Montréal 126, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Peplow Transport Ltd.avec sa requête datée le 10 septembre 1973.With regard to the security given in the case of Peplow Transport Ltd.with its application dated September 10, 1973.Rôle M-484 SS3-V-S-1 THE ALUMINUM COMPANY OF CANADA, Box 269, Toronto Dominion Centre, Toronto, Ontario.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Baylor Transport Limited avec sa requête datée le 29 août 1973.With regard to the security given in the case of Baylor Transport Limited with its application dated August 29, 1973.Rôle M-185 SS4-V-S-1 CANADA PACKING LTD.1260, rue Mill.Montréal.P.Q.Rôle M-486 SS4-V-S-2 CANADA PACKERS LTD.1260, rue Mill.Montréal, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Hawlev Transport avec sa requête datée le 31 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Manthaller Transport avec sa requête datée le 31 août 1973.With regard to the security given in the case of Hawley Transport with its application dated August 31, 1973.With regard to the security given in the case of Manthaller Transport with its application dated August 31st, 1973, Rôle M-487 SS4-V-S-3 CANADA PACKERS LTD., 1260, rue Mill, Montréal.P.Q.Rôle M-488 SS4-V-S-4 CANADA PACKERS LTD.1260.rue Mill, Montréal, P.Q.Rôle M-489 SS4-V-S-5 CANADA PACKERS LTD., 1260.rue Mill, Montréal.P.Q.Rôle M-490 8S3-V-S-2 THE ALUMINUM COMPANY OF CANADA, Box 269, Toronto, Dominion Centre, Toronto, Ontario.Rôle M-491 SS3-V-S-3 THE ALUMINUM COMPANY OF CANADA, Box 269, Toronto Dominion Centre, Toronto, Ontario.Rôle M-492 SS5-V-S-1 PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200.rue St-Jacques, Oième étage, Montréal 126.P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause Powers Transport, avec sa requête datée le 31 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Terry's Transport avec sa requête datée le 31 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause Kusmam Transport avec sa requête datée le 31 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Cooney Haulage Limited avec sa requête datée le 29 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Cooney Haulage Limited avec sa requête datée le 29 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Venspeeteen Cartage Ltd, avec sa requête datée le 31 août 1973.With regard to the security given in the case of Powers Transport with its application dated August 31st, 1973.With regard to tlie security given in the case of Terry's Transport with its application dated August 31st, 1973.With regard to the security given in the case of Kusmann Transport with its application dated August 31st.1973.With regard to the security given in the case of Cooney Haulage Limited with its application dated August 29, 1973.With regard to the security given in the case of Cooney Haulage Limited with its application dated August 29, 1973.With regard to the security given in the esse of Venspeeteen Cartage Ltd.with its application dated August 31st, 1973. 6402 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Rôle M-493 SS5-V-S-2 PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200.rue St-Jacques.9ième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-495 SS5-V-S-3 PAQUETTE.PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques.Oième étage.Montréal 126.P.Q.Rôle M-494 SS5-V-S-4 PAQUETTE.PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200.rue St-Jacques, 9ième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-497 SS5-V-S-5 PAQUETTE.PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 220, rue St-Jacques.9ième étage, Montréal 126.P.Q.Rôle M-496 SS5-V-S-6 PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques.9ième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-498 SS6-V-S-1 PEACOCK BROTHERS LIMITED, 260.St-Patrick.LaSalle 660, P.Q.Rôle M-499 SS7-V-S-1 GARAGE MAURICE LECOMPTE, 2150, rue Francis Hughes, Ville de Laval.P.Q.Rôle M-473 SS8-V-S-1 EMPIRE STEVEDOVING CO.LTD., 300, rue St-Sacrement, Montréal, P.Q.Rôle M-474 SS5-V-S-7 PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques.9ième étage, Montréal 126.P.Q.Rôle M-475 SS9-V-S-1 OK EXPRESS CO.LTD., 2671, Mankham Road, P.O.Box 280, Agincourt, Ontario.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Charles Harris & Sons Transport Limited avec sa requête datée le 31 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Walmer Transport Co.Ltd.avec sa requêle datée le 4 septembre 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Matthew F.Donovan, avec sa requête datée le 4 septembre 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Murray's Express Service Ltd, avec sa requête datée le 30 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.André Alix avec sa requête datée le 31 août 1973.Relativement au cautionnement lourni dans la cause de Hot Shot Trucking Co.avec sa requête datée le 31 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Garage Maurice Lecompte avec sa requête datée le 29 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Truk-King Services Ltd.avec sa requête datée le 29 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.Harold A.Sweet avec sa requête datée le 27 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de OK Express Co.Ltd.avec sa requête datée le 27 août 1973.With regard to the security given in the case of Charles Harris & Sons Transport Limited with its application dated August 31st.1973.With regard to the security given in the case of Walmer Transport Co.Ltd.with its application dated September 4.1973.With regard to the security given in the case of Matthew F.Donovan with his application dated September 4, 1973.With regard to the security given in the case of Murray's Express Service Ltd.with its application dated August 30, 1973.With regard to the security given in the case of Mr.André Alix with his application dated August 31st, 1973.With regard to the security given in the case of Hot Shot Trucking Co.with its application dated August 31st.1973.With regard to the security given in the case of Garage Maurice Lecompte with its application dated August 29, 1973.With regard to the security given in the case of Tmk-King Services Ltd.with its application dated August 29.1973.With regard to the security given it the case of Mr.Harold A.Sweet with his application dated August 27, 1973.With regard to the security given in the case of OK Express Co.Ltd.with its application dated August 27.1973. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n° U 6403 Rôle M-476 SS10-V-S-1 WALTER GOSNELL, R.R.No 2.Dutton, Ontario.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.Walter Gossnell avec sa requête datée le 27 août 1973.With regard to the security given in the case of Mr.Walter Gossnell with his application dated August 27, 1973.Rôle M-477 SS11-V-S-1 IVAN DENNING, R.R.No 1, Dutton, Ontario.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.Ivan Denning avec sa requête datée le 27 août 1973.With regard to the security given in the case of Mr.Ivan Denning with his application dated August 27, 1973.Rôle M-478 SS12-V-S-1 CONSOLIDATED BATHURST LIMITED, 800, Dorchester Blvd.West.Montréal, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Hendrie Cartage Limited avec sa requête datée le 28 août 1973.With regard to the security given in the case of Hendrie Cartage Limited with its application dated August 28, 1973.Rôle M-179 SS13-V-S-1 CONSOLIDATED BATHURST LIMITED, 800, Dorchester Blvd.West.Montréal.P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Buckley Cartage Limited avec sa requête datée le 28 août 1973.With regard to the security given in the case of Buckley Cartage Limited with its application doted August 28, 1973.Rôle M-480 SS14-V-S-1 CONSOLIDATED BATHURST LIMITED, 800, Dorchester Blvd.West, Montréal, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Anderson Cartage Limited avec sa requête datée le 28 août 1973.With regard to the security given in the case of Anderson Cartage Limited with its application dated August 28.1973.Rôle M-481 SS15-V-S-1 CONSOLIDATED BATHURST LIMITED, 800, Dorchester Blvd.West, Montréal, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Livingstone Transportation Limited avec sa requête datée le 28 août 1973.With regard to the security given in the case of Livingstone Transportation Limited with its application dated August 28, 1973.Rôle M^82 SS16-V-S-1 CONSOLIDATED BATHURST LIMITED, 800, Dorchester Blvd.West, Montréal.P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de B & R.Transportation Limited avec sa requête datée le 28 août 1973.With regard to the security given in the case of B & R.Transportation Limited with its application dated August 28, 1973.Rôle M-520 15601-V DUNHAM TRANSPORT LIMITED, Percy St.Colborne, Ontario.Rôle M-528 SS3-V-S-4 THE ALUMINUM COMPANY OF CANADA, Box 269, Toronto Dominion Centre, Toronto, Ontario.Rôle M-529 SS3-V-S-5 THE ALUMINUM COMPANY OF CANADA.Box 269, Toronto Dominion Centre, Toronto, Ontario.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Dunham Transport Limited (15601-V) avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Boyd Transport Limited avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Boyd Transport Limited avec sa requête datée le 24 août 1973.With regard to the security given in the case of Dunham Transport Limited (15601-V) with its application dated August 28, 1973.With regard to the security given in the case of Boyd Transport Limited with its application dated August 28, 1973.With regard to the security given in the case of Boyd Transport Limited with its application dated August 24, 1973. 6404 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, Norember 3.1973.Vol.105, No.U Rôle 11-888 870-V-S-l GEO.A.HALL CARTAGE CO.LTD., 1281.rue Condc, Montréal 104, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dan» la cause de Geo.A.Hall Cartage Ltd.(870-V) avec sa requête datée le 28 août 1973.With regard to the security given in the case of Geo.A.Hall Cartage Ltd.(870-V) with its application dated August 28, 1973.Rôle M-532 2873-V-S-l LAMOTHE QUEBEC INC., Rouyn.P.Q.Rôle M-531 13631-V-S-I PAQUETTE, PAQUETTE.PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques.9ième étage.Montréal.P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Lamothe Québec Inc.(2873-V) avec sa requêle datée le 29 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Stanley W.Ward (13631-V) avec sa requête datée le 28 août 1973.With regard to the security given in (he case of Lamothe Québec Inc.(2873-V) with its application dated August 29, 1973.With regard to the security given in the case of Stanley W.Ward (13631-V) with his application dated August 28.1973.Rôle M-530 3291-V-S-l J.A.DORE TRANSPORT INC., 4207, St-Ambroise, Montréal, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de J.A.Doré Transport Inc.(3291-V') avec sa requête datée le 7 septembre 1973.With regard to the security given in the case of J.A.Doré Transport Inc.(3291-V) with its application dated September 7, 1973.Rôle M-534 6793-V-S-5 PAQUETTE.PAQUETTE.PERREAULT & RIVET.200.rue St-Jacques.9iême étage.Montréal.P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Brazeau Transport Inc.(6793-V) avec sa requête datée le 14 août 1973.With regard to the security given in the fane of Brazeau Transport Inc.(6793-V) with its application dated August 14, 1973.Rôle M-535 6793-V-S-6 PAQUETTE.PAQUETTE, PERREAULT 4 RIVET.200, rue St-Jacques.9ième étage.Montréal 126.P.Q.Relativement au cautionnement fourni dan» la cause de Brazeau Transport Inc.(6793-V) avec sa requête datée le 14 août 1973.With regard to the security given in the rase of Brazeau Transport Inc.(6793-V) with its application dated August 14, 1973.Rôle M-538 10201-V-S-l CONTAINER EXPRESS INC., 434, St-Francois-Xavier.Montréal 125, P.Q.Relativement au cautionnement fourni flans la cause de Container Exprès» Inc.(10201-V) avec sa requête datée le 30 août 1973.With regard to the security given in the case of Container Express Inc.(10201-V) with its application dated August 30, 1973.Rôle M-536 9570-V-S-l COUTU TRANSPORT EXPRESS LTEE, Rouyn, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Coutu Transport Express Ltée (9670-V) avec sa requête datée le 29 août 1973.With regard to the security given in the case of Coutu Transport Express Ltée (9570-V) with its application dated August 29, 1973.Rôle M-537 10201-V-S-2 CONTAINER EXPRESS INC., 434, St-Francois-Xavier, Montréal 125, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Container Express Inc.(10201-V) avec sa requête datée le 28 août 1973.With regard to the security given in the cuse of Container Express Inc.(10201-V) with its application dated August 28, 1973.Rôle M-539 2630-V-S-l ALLEN'S CARTAGE LIMITED, 1785.Cabot St.Montréal 205.P.Q.Relativement au cautionnement fourni dan» la cause de Allen's Cartage Limited (2530-V) avec sa requête datée le 31 août 1973.With regard to the security given in the case of Allen's Cartage Limited (2630-V) with its application dated August 31, 1973. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, «\" U 6405 Hôle M-540 21947-V-S-l PAQUETTE, PAQUETTE.PERREAULT & RIVET.200, rue St-Jacques.Oième étage.Montréal 126, P.Q, Rôle M-478 SS12-V-S-1 HENDRIE CARTAGE LIMITED, 800, Dorchester Blvd.West.Montréal.P.Q.R6le M-479 SS13-V-S-1 BUCKLEY CARTAGE, SOO.Dorchester Blvd.West.Montréal, P.Q.Hole M-480 SS14-V-S-1 ANDERSON CARTACE LIMITED, 800, Dorchester Blvd.West, Montreal.P.Q.Rôle M-481 SS15-V-S-1 LIVINGSTONE TRANSPORTATION LTD., 800, Dorchester Blvd.West.Montréal, P.Q.Rôle M-482 SS16-V-S-1 B & R TRANSPORTATION LTD., 800, Dorchester Blvd.West, Montréal, P.Q.Rôle M-483 SS2-V-S-2 STIKEMAN & ELLIOT TAMAKI MERCIER & ROBB, 1155, Dorchester Blvd.West, Montréal, P.Q.Rôle M-501 4373-V-S-l MICHEL TRANSPORT INC., 4.rue Union, Arthabaska, P.Q.Rôle M-502 1012-V-S-l PROVOST EXPRESS & TRANSPORT INC., CP.10, Marieville, P.Q.Rôle M-503 I019-V-S-1 TOTRAN LTEE, 6000, Notre-Dame ouest, Montréal 208, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Normand Bélanger (21947-V) avec sa requête datée le 17 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Hendrie Cartage Limited avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Buckley Cartage Limited avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Anderson Cartage Limited avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Livingstone Transportation Limited avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de B & R Transportation Limited avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Municipal Tank Lines Ltd.avec sa requête datée le 29 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Michel Transport Inc.(4373-V) avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Provost Express & Transport Inc.(1012-V) avec sa requête datée le 20 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Totran Ltée (1019-V) avec sa requête datée le 28 août 1973.With regard to the security given in the case of Normand Bélanger (21947-V) with his application dated August 17.1973.With regard to the security given in the case of Hendrie Cartage Limited with its application dated August 28.1973.With regard to the security given in the case of Buckley Cartage Limited with its application dated August 28, 1973.With regard to the security given in the case of Anderson Cartage Limited with its application dated August 28.1973.With regard to the security given in the case of Livingstone Transportation Limited with its application dated August 28.1973.With regard to the security given in the case of B & R.Transportation Limited with its application dated August 28.1973.With regard to the security given in the case of Municipal Tank Lines Ltd.with its application dated August 29, 1973.With regard to the security given in the case of Michel Transport Inc.(4373-V) with its application dated August 28, 1973.With regard to the security given in the case of Provost Express & Transport Inc.(1012-V) with its application dated August 20.1973.With regard to the security given in the case of Totran Ltée (1019-V) with its application dated August 28.1973. 6406 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3.1973, Vol.10S, No.U Rôle -M-504 6577-V-S-l ASBESTOS EXPRESS LTD., CP.71, Asbestos.P.Q.Rôle M-506 13963-V-S-l PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, 9ième étage, Montréal, P.Q.Rôle M-505 20590-V-S-l PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, Oième étage.Montréal 126.P.Q.Rôle M-507 23405-V-S-l PAQUETTE.PAQUETTE.PERREAULT & RIVET, 200.rue St-Jacques.Oième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-500 13579-V-S-l LAFORTUNE TRANSPORT LTEE, 47, rue Forest.LAssomption, P.Q.Rôle M-508 11355-V-S-l MAISLIN TRANSPORT LTD., 7401, Boul.Newman.LaSalle, P.Q.Rôle M-515 23321-V-S-l PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, Oième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-511 7737-V-S-l PAQUETTE.PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques.9ième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-514 23321-V-S-2 GEORGE A.LEWIS LTD., St-Stephens, N.B.Rôle M-509 851-V-S-l HIGHWAY TRANSPORTATION BROKERS INC.561, Boul.Crémazie est, Suite 23, Montréal 354, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Asbestos Express Ltd.(6577-V) avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Speedway Express Limited avec sa requête datée le 2i août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Maheu Transport Inc.avec sa requête datée le 13 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.Robert Dion avec sa requête datée le 14 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Lafortune Transport Inc.avec sa requête datée le 27 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Maislin Transport Ltd.avec sa requête datée le 12 septembre 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de George A.Lewis Limited avec sa requête datée le 30 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Bellechi-sse Transport Inc.avec sa requête datée le 3 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de George A.Lewis Ltd.avec sa requête datée le 27 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Dubois Transport avec sa requête datée le 31 août 1973.With regard to the security given in the case of Asbestos Express Ltd.(6577-V) with its application dated August 28, 1973.With regard to the security given in the case of Speedway Express Limited with its application dated August 21, 1973.With regard to the security given in the case of Maheu Transport Inc.with its application dated August 13, 1973.With regard to the security given in the case of Mr.Robert Dion with his application dated August 14, 1973.With regard to the security given in the case of Lafortune Transport Inc.with its application dated August 27, 1973.With regard to the security given in the case of Maislin Transport Ltd, with its application dated September 12, 1973.With regard to the security given in the case of George A.Lewis Limited with its application dated August 30, 1973.With regard to the security given in the case of Bellechasse Transport Inc., with its application dated August 3.1973.With regard to the security given in the case of George A.Lewis Ltd.with its application dated August 27, 1973.With regard to the security given in the case of Dubois Transport with its aplica-tion dated August 31st, 1973. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n' U 6407 Rôle M-512 23406-V-S-l PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, Oième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle M-513 21992-V-S-l PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, Oième étage.Montréal 126, P.Q.Rôle M-510 12940-V-S-l PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques.9ième étage, Montréal 126.P.Q.Rôle M-516 7677-V-S-l AUDET EXPRESS INC.284, rue Thibeau.Cap-de-la-Madeleine.Cté Champlain, P.Q.Rôle M-517 1256-V-S-l A.& F.BAILLARGEON EXPRESS INC., 5600.rue Ferrier.Montréal 307.P.Q.Rôle M-518 SS18-V-S-1 A * F BAILLARGEON TRUCK & TRAILER RENTAL INC., 5600, rue Ferrier, Montréal 307, P.Q.Rôle M-519 7883-V-S-l SEAWAY CARTAGE LTD., 2125.Théodore.Montréal 404.P.Q.Rôle M-526 21958-V-S-l PAQUETTE, PAQUETTE.PERREAULT A RIVET, 200, rue St-Jacques, Oième étage.Montréal 126, P.Q.Rôle M-527 21958-V-S-2 PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, 9ième étage.Montréal 126, P.Q.Rôle M-521 15602-V-S-2 CANADA PACKERS LTD., 1260, rue Mill.Montréal, P.Q.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de M.Adamo Salvati, avec sa requête datée le 13 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Arnold Brother Ltd.avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Beaulieu Transport Ltée avec sa requête datée le 27 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Audet Express Inc.avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause A & F Baillargeon Express Inc.avec sa requête datée le 24 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans ta cause de M.Robert Major, avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Seaway Cartage Ltd.(7S83-V) avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Laidlaw Transport Ltd.(21958-VI avec sa requête datée le 28 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Laidlaw Transport Ltd.(21958-V) avec sa requête datée le 29 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Fruit.Belt Produce Trucking Limited (15602-V; avec sa requête datée le 29 août 1973.With regard to the security given in the case of Mr.Adamo Salvati, with his application dated August 13, 1973.With regard to the security given in the case of Arnold Brother Ltd.with its application dated August 28.1973.With regard to the security given in the case of Beaulieu Transport Ltée with its application dated August 27, 1973, With regard to the security given in the case of Audet Express Inc.with its application dated August 2S.1973.With regard to the security given in the case of A & F Baillargeon Express Inc.with its application dated August 24, 1973.With regard to the security given in the case of Mr.Robert Major with his application dated August 28.1973.With regard to the security given in the case ol Seaway Cartage Ltd (7883-V) with its application dated August 28.1973.With regard to the security given in the case of Laidlaw Transport Ltd.(21958-V) with its application dated August 28.1973.With regard to the security given in the case of Laidlaw Transport Ltd.(21958-V) with its application dated August 29, 1973.With regard to the security given in the case of Laidlaw Transport Ltd.(21958-V) with its application dated August 29, 1973. 6408 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973.Vol.105, No.U Rôle M-522 15602-V-S-2 CANADA PACKERS LTD., 12G0.rue Mill.Montréal, P.Q.Rôle M-523 15600-V-S-l DRUKER SILVERMAN & CO., 4333.St.Catherine St.West, Montreal 215, P.Q.Rôle M-524 SS1-V-S-2 PAQUETTE.PAQUETTE.PERREAULT & RIVET.200.rue St-Jacques, Oième étage.Montréal, P.Q.Rôle M-525 87V-S-2 PAQUETTE.PAQUETTE.PERREAULT & RIVET, 200, rue St-Jacques, Oième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle Q-321 10409-V-P-l LUCIEN HEON, 1590.boul.St-Louis, St-Louis de France, Cté de Champlain, P.Q.54207-o Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Fruit Belt Produce Trucking Limited (15602-V) avec sa requête datée le 30 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Mel's Express Ltd.(15600) avec sa requête datée le 30 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Peplow Transport Ltd.avec sa requête datée le 31 août 1973.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Finch & Sons Transport Ltd.(87-V) avec sa requête datée le 13 août 1973.Relativement à une correction de la décision signifiée au requérant le 27 août 1973.par laquelle on accordait un transfert de permis de camionnage de Lucien Hétu en faveur de Transport Capco Inc.alors que le nom de ce détenteur est Lucien Héon.With regard to the security given in the case of Fruit Belt Produce Trucking Limited ' 15602-V) with its application dated August 30.1973.With regard to the security given in the case of Mel's Express Ltd.(15600) with its application dated August 30, 1073.With regard to the security given in the case of Peplow Transport Ltd.with its application dated August 31, 1973.With regard to the security given in the case of Finch & Sons Transport Ltd.(87-V) with its application dated August 13.1973.With regard to a correction of the decision notified to the applicant on August 27, 1973.by which was granted the transfer of trucking permit of Lucien Hétu in favour of Transport Capco Inc., while the name of the permit holder is Lucien Héon.II \u2014 Avis d'introduction de requête : La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.II \u2014 Notice of submission of application : Tlie Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.Application for permit.The applicant requests the following permit: (a) Restricted trucking - local service -contract - (a) Chicoutiini and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said City, for the transportation of light parcels, non-stamped and non-sealed mail, with a regular car and/or station-wagon (taxi), on behalf of Bell Canada Ltée.; (b) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (b) From Chicoutimi to all points located within the provincial electoral districts of Chicoutimi.Jonquicre, Dubuc, Roberval, Lac St.Jean, Chailevoix and Saguenay, and return, for the transportation of light parcels, non-stamped and non-sealed mail, with a regular car and/or station-wagon (taxi), on behalf of Bell Canada Ltée.Rôle Q-296 23475-V-D-l OCTAVE COTE.22.rue St-Vincent est.App.No 6.Chicoutimi.P.Q.Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant: a) Transport restreint - service local - contrat- o) Chicoutimi et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pourle transport de colis légers, de malle nen timbrée et non cachetée, avec automobile ordinaire et/ou station wagon (taxi), |Ktur le compte de Bell Canada Ltée.; b) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - b) De Chicoutimi a lous points situés dans les districts électoraux-provinciaux de Chicoutimi, Jonquière, Dubuc, Roberval, Luc St-Jean, Charlevoix et Saguenay, et retour, pour le transport de colis légers, de malle non timbrée et non cachetée, avec automobile ordinaire et/ou station wagon (taxi), pour le compte de Bell Canada Ltée. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 106' année, n° U 6409 Rôle Q-297 14134-V-D-2 PIERRE JORON SERVICE LIMITEE.362, avenue Savard, Chicoutimi, Cté Chicoutimi.Rôle Q-298 15957-V-D-19 CERARD NOL1N LIMITEE, Parc Industriel, CP.100, 150, rue de l'Eglise, St-Jean Chrysostome, Cté Lévis.Rôle Q-299 23474-V-D-l JULIEN BUJOLD, 565, rue Doucet, Rimouski, P.Q.Rôle Q-300 12926-V-D-l GERMAIN LEBLANC, (décédé / deceased) 6, rue Gingras, Warwick, Cté Arthabaska.et SUCCESSION GERMAIN LEBLANC, 6.rue Gingras.Warwick.Cté Arthabaska.Rôle Q-301 15957-V-D-20 CERARD NOLIN LIMITEE, 150.De l'Eglise.St-Jean Chrysostome.Cté Lévis.Rôle Q-302 23476-V-D-l DENIS ROYER, St-Isidore, Cté Dorchester.Modification de permis (droit additionnel).La partie requérante demande à la Commission d ajouter à son permis l'autorisation suivante: Droit additionnel : La détentrice est autorisée ù louer, à long terme (5 ans), de While Motor Corporation of Canada Ltd.permis 723-DYV.trois (3) camions-tracteurs dont la description appa-ratt au contrat de location déposé à la Commission.Autocar 1973 Série 72505 Autocar 1973 Série 72846 Autocar 1973 Série 72846 Modification de permis (courtier).La partie requérante demande le permis suivant: Service de courtier en transport pour le transport de marchandises autorisé par les clauses a h q inclusivement de son permis No 15957-V.en utilisant le service de remorquage de: Julien Uni.M.365.rue Doucet.Rimouski, P.Q.23474-V.Demande de permis île remorquage.La partie requérante demande le permis suivant: Transport par remorquage (haulaway) seulement - contrat Remorquage avec ses tracteurs dûment enregistrés des remorques vides ou remplies, selon les clauses a h q inclusivement du permis No 15957-V.pour le compte de: Gérard Nolin Limitée.Parc Industriel.CP.100.ISO.rue de l'Eglise.St-Jean Chrysostome.Cté Lévis.15957-V.Cession de la propriété du système de transport (décès).La Succession Germain Leblanc demande que lui soit cédée la propriété du système de transport, ci-après décrit, qu'exploitait de son vivant Monsieur Germain Leblanc.Transport Général - service local.- Warwick et tous le.» endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite localité; Transport général-longue distonce-rayon- De Warwick à tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 30 milles des limites de ladite localité, et retour; Transport général - longue distance - route restreinte - De Warwick à Montréal, et retour; Transport restreint-longue distance-rayon - contrat - De Warwick à tous les endroits situés dans un rayon de 150 milles des limites dudit endroit, a l'exception de Québec et Montréal, et retour, pour le transport de marchandises, pour le compte de Georges E.Ling Limitée de Warwick.Modification de permis (courtier).La partie requérante demande le permis suivant: Service de courtier en transport pour le transport de marchandises autorisé par les clauses a à q inclusivement de son permis No 15957-V, en utilisant le service de remorquage de: Denis Royer, St-Isidore.Cté Dorchester.23476-V.Demande de permis ce remorquage.La partie requérante demande le permis suivant: Transport par remorquage (haulway) seulement - contrat - Modification of permit (additional right).The applicant requests from the Commission the addition of the following authorization to his permit: Additional right : The permit holder is authorized to lease on a long-term basis (5 years), from White Motor Corporation of Canada Ltd., permit 723-DYV.three (3) trucks-tractors whose description appeurs in the leasing contract filed with the Commission.Bus 1973 Serial number 72505 Bus 1973 Serial number 72845 Bus 1973 Serial number 72846 Modification of permit (broker).The applicant requests the following permit: Trans|iort broker service for the transportation of goods authorized by clauses a to 7 inclusive of its carrier's permit No.15967-V, utilizing the haulaway Service provided by: Julien Bujold, 365 Doucet Street, Rimouski.P.Q.23474-V.Application for a haulaway permit.The applicant requests the following permit : Haulaway transportation only - contract - Haulaway of empty or loaded trailers, with his tractors duly registered, according to clauses a to q inclusive of the Litter's permit No.15957-V.on behalf of: Gérard Nolin Limitée.Parc Industriel.P.O.Box 100.150 De l'Eglise Street, St.Jean-Chrysos-tome.County of Lévis.15957-V.Transfer of ownership of a transport service (death).The estate of Germain Leblanc requests that ownership of the transport service hereinafter described be transferred to it.the said transport service having been operated by Mr.Germain Leblanc in his lifetime.General trucking - local service - Warwick nnd all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said locality; General trucking - long distance - radius - From Warwick to all points located over a distance of not more than 30 miles from the limits of said locality, and return; General trucking - long distance - restricted route - From Warwick to Montreal, and return: Restricted trucking - longdistance - radius - contract - From Warwick to all points located within a radius of 150 miles from the limits of said Town, with the exception of Québec and Montreal, and return, for the transportation of goods of behalf of Georges E.Ling Limitée, of Warwick.Modification of permit (broker).The applicant requests the following permit : Transport broker service for the transportation of goods authorized by clauses a to q inclusive of its carrier's |>ermit No.15957-V.utilizing the haulaway service provided by: Denis Rover, St.Isidore.County of Dorchester.23470-V.Request for haulaway permit.The applicant requests the following permit: Haulaway transportation only - contract - 6410 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Rôle Q-303 17484-V-D-2 223G7-V-D-2 MONTREAL CHIBOU- GAMAU TRANSPORT ENRG., 3.rue Ste-Anne.St-Félicien, clé Lac St-Jean.et LE TRANSPORT DU NORD (1971) INC.CP.158, St-Prime.cté Lac St-Jean.Rôle Q-304 1539-A D-l TK AUTOBUS CHEVRETTE INC.621.rue St-Louis.La Tuque, Cté Champlain, P.O.Rôle Q-305 2155-A D-l TF HERVE LEHOUX.246, Messel.Coleraine, Cté Mégantic.P.Q.Rôle Q-306 BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC., Suite 400, Edifice Girardin.1259.rue Bern.Montréal 132.P.Q.Pour/For: GU1LBAULT TRANSPORT INC.Rôle Q-307 524-V D-l TF J.B.BAILLARCEON EXPRESS LIMITEE.5045, est rue Ontario, Montréal 404, P.Q.Remorquage avec ses tracteurs dûment enregistrés des remorques vides ou remplies, selon les clauses a àq inclusivement du permis No 15957-V.pour le compte de: Gérard Nolin Limitée.150.De l'Eglise.St-Jean Chrysostome, Cté Lévis.15957-V.Amendement de la requête 17484-V-D-l publiée dans la G.O.Q.No 34.du 25 août 1973.page 4918.« Les requérantes se sont adressées à la Commission des transports du Québec pour amender la demande de cession de la propriété d'un système de transport qui a été publiée dans la Gazette officielle du 25 août 1973, volume 105, numéro 34.page 4918 de façon a y ajouter la disposition suivante: A l'occasion du transfert du permis No 17484-V, la restriction qui s'y trouve concernant le contrôle des compagnies expéditrices et du propriétaire du système de transport sera éliminée.» Demande d'augmentation de tarif pour le transport d'étudiants: Taux actuels: Taux proposés: $0.10 Passage simple $0.15 5 bil.0.50 Billets 8 billets.1.00 Demande d'augmentation de taux pour le transport de Coleraine à Lake Asbestos: Ancien taux : 32.50 pur semaine Taux proposé: S3.00 par semaine Demande de fixation de taux: Supplément interim No 1824.13e révision.Demande de modification de taux dans les régions de Québec et Trois-Rivières comme suit: Haulaway of empty or loaded trailers, with his duly registered tractors, according to clauses a to ?inclusive of the latter's jiermit No.15957-V.on behalf of: Gérard Nolin.150 De l'Eglise.St.Jean-Chrysos-tome, County of Levis.15957-V.Amendment of request 17484-V-D-l published in the Q.O.G.No.34.dated August 25.1973.page 491S.\"The applicants have requested from the Québec Transport Commission authorization to amend the request of transfer of ownership of the transport service, which was published in the Quebec Official Gazelle of August 25, 1973.Volume 105, number 34.page 4918, in order to add the following provision: At the time of the transfer of permit No.17484-V.the restriction which appears therein respecting the control of shipping companies and the owner of the transport service shall be withdrawn.\" Application for increase in tariffs for the transportation of students: Present rates: Proposed rates: $0.10 single fare $0.15 5 tickets 0.50 tickets s tickets 1.00 Application for an increase in rates for the transport from Coleraine to Lake Astestos: Former rates: Proposed rates: $2.50 per week $3.00 per week Application for fixing of rates: Interim Supplement No.1824.13th revision Application for the following modification in rates for the regions of Québec and Trois-Rivières: Déménagements / Marina Camion - 2 hommes / Truck - 2 men Hommes supplémentaires - chacun / Each addilional man Pianos, réfrigérateurs, cuisinières et congélateurs l'ianoi.refrigerators, stores and freezer! Taux à l'heure ci-haut mentionnés - Minimum: 2 heures / Same hourly rate as above Minimum: S hours Transport lourd tel que: machinerie, coffres-forts, etc.: Heavy transport such as: machinery, safes, etc.Camion (5 tonnes) - 3 hommes - avec équipement spé-cial / Truck (5 tons) - S men - with special equipment Camion (5 tonnes) - 4 hommes - avec équipement et treuil pour polanquage / Truck (5 tons) - 4 men - with equipment and hauling winch Hommes supplémentaires - chacun / Each additional man Taux horaires proposes Proposed Hourly rates $20.00 6.50 Taux horaires actuels Present Hourly rates $18.00 6.00 27.50 34.00 6.50 25.00 31.00 6.00 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n' U 6411 Rôle Q-808 346-V D-l TV LA COMPAGNIE DE TRANSPORT ST- MAURICE, 503, rue St-Maurice, Trois-Rivières, Cté St-Maurice.P.Q.Rôle Q-309 45-N D-l TF CAPITAINE PAUL-EUGENE LAVOIE, Ile-aux-Grues.Cté Montmagny.P.Q.Rôle Q-312 9 CF.D-3 MINISTRE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, Hôtel du Gouvernement, Québec, P.Q.Rôle Q-313 13175-V-D-2 GRONDIN TRANSPORT INC., St-Frédéric, Cté Beauce.Temps supplémentaire: Après 5:00 p.m.du lundi au vendredi et le samedi toute la journée: temps et demi sur les taux ci-haut mentionnés.Après minuit, et jours fériés: temps double sur les taux ci-haut mentionnés.Demande de fixation de taux pour le transport de voyageurs dans les services urbains de: Trois-Rivières.Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières ouest.De: Shawinigan, Shawinigan sud, la Baie-Shawinigan.De: Grand-Mère, St-Georges.Taux proposés: Passage comptant S0.30 En série: 4 passages pour: 1.00 Ecoliers autorisés: 10 passages pour: 1.50 Correspondance: 0.05 Demande d'augmentation de tarifs pour le service de bateau-passeur entre Montmagny et l'Ile-aux-Orues.Requête pour installation d'un système de protection automatique à une traverse à niveau.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de rendre une Ordonnance autorisant l'installation d'un système de protection automatique au passage à niveau de la route 13S (15) à travers la voie de chemin de fer Romaine River, dans la municipalité de Havre-St-Pierre, Cté de Duplessis; elle expose respectueusement que: 1) pour la sécurité, la protection et la commodité du public, il y a lieu d'installer un système de protection automatique au passage à niveau ci-dessus décrit: 2) le coût d'installation de ce système de protection automatique sera entièrement payé par le ministère des Transports.3) Les frais d'entretien et d'opération du-dit système de protection automatique seront entièrement payés par le chemin de fer Romaine River.Modification de la clause Clause concernée: j) Transport restreint - longue distance route restreinte - contrat - j) De St-Frédéric (Beauce) aux frontières Québec-Etats-Unis (tous ports d'entrée).Destination: Les Etats suivants: Massachusetts.Rhode Island, Vermont, Connecticut, pour le transport d'amiante, et retour avec marchandises refusées, sacs vides et palettes, pour le compte de Carey Canadian Mines Ltd.La partie requérante demande d ajouter a la clause j de son permis ^'autorisation suivante: .En donnant le service mentionné à la clause ; de son permis, la détentrice est autorisée à utiliser les plaques C.T.Q.amovibles pour les fixer sur des châssis vides ou chargés provenant de ou destinés par voies terrestres aux Etats du Massachusetts, Rhode Island, Vermont et Connecticut, châssis appartenant à Sea-Land Service Inc.et qui sont remorqués sur les routes de la province de Québec, entre la frontière américaine et St-Frédéric ou toute municipalité dans un rayon Overtime: After 5:00 o'clock p.m.from Monday through Friday including Saturday all day: time and ahalf over the aforesaid rates.After midnight and on holidays: double time over the aforesaid rates.Application for fixing of rates for the transportation of passengers in the urban services of: Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine,Trois-Rivières-West.From: Shawinigan, Shawinigan South, Baie-Shawinigan.From: Grand'Mère, St.Georges.Cash fares-Series: 4 tickets for: Authorized pupils: 10 tickets for: Transfer: Proposed rates SO.30 1.00 1.50 0.05 Application for increase in tariffs for the fern.- service between Montmagny and Ile-aux-Grues.Application for the installation of an automatic protection system at a railroad crossing.The applicant requests the Québec Transport Commission to issue an Order authorizing the installation of an automatic protection system at the grade crossing on Highway 138 (15) across the Romaine River Railway in the Municipality of Havre-St.Pierre, County of Duplessis; it respectfully states that : (1) for the security, protection and convenience of the public, there is ground to set up an automatic protection system at the aforesaid grade crossing; (2) the installation cost of this automatic protection system shall be paid by the Department of Transport.(3) The maintenance and operating costs of said automatic protection system shall be entirely borne by the Romaine River Railway.Modification of clause /.Clause concerned: 0') Restricted trucking - long distance -restricted route - contract- 0') From St.F\"rédéric (Beauce) to the Quebec-United States border (all ports of entry).Destination: the following States: Massachusetts.Rhode Island, Vermont, Connecticut, for the transportation of asbestos and return with refused goods, empty bags and palets, on behalf of Carey Canadian Mines Ltd.The applicant requests that the following authorization be added to clause j of its permit: In operating the service mentioned in clause 3 ol its permit, the holder is authorized to utilize removable Q.T.C.plates to affixed them on the empty or loaded chassis coming from or going, to by road, the States of Massachusetts, Rhode Island, Vermont and Connecticut, said chassis belonging to Sea-Land Service Inc., and which are hauled on the highways of the Province of Québec, between the American border and St.Frédéric or any municipality located within a 6412 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol 105, No.U Rôle Q-314 2779-A-D2 MONSIEUR LEON CLOUTIER, Route Kennedy, St-Joseph de Beauce.Cté Beauce, P.Q.Rôle Q-31Ô 2779-A-D1 MONSIEUR LEON CLOUTIER, Route Kennedy.St-Joseph de Beauce, Cté Beauce, P.Q.de cinq (5) milles.Le tout sans préjudice à tout droit pouvant être exigé de la province de Québec concernant l'enregistrement desdits châssis.Droit additionnel: Requête pour obtenir le droit additionnel suivant: Classe permis: Autobus.Service: Voyages spéciaux ou :i charte partie de Sts-Anges, Cté Beauce et St-Sévérin, Cté Beauce :\\ tous points dnns la province de Québec.Droit additionnel: Requête pour obtenir les droits additionnels suivants: Classe permis: Autobus.Service : a) Transport d'écoliers de leur résidence de Ville St-Joseph et paroisse et St-Joseph-des-Erables aux écoles de St-Joseph et retour.ft) Transport d'écoliers de leur résidence de St-Jules aux écoles de Pt-Jules et St-Joseph et retour.c) Transport d'écoliers de leur résidence de St-Odilon et paroisse à l'école de St-Odilon et de St-Joseph et retour.tt) Transport d'écoliers résidant dans la Ville St-Joseph et paroisse Sts-Anges, Framp-ton.St-Odilon, St-Jules, St-Séverin, Tring-Jonction, St-Frédéric, Vallée-Jonction, et qui transfèrent à Ville St-Joseph (aux écoles) et fréquentant les écoles de Beauceville et St-Georges et retour.e) Transport écoliers de Ville St-Joseph et paroisse le midi des écoles de Ville St-Joseph à leur résidence située dans Ville St-Joseph et paroisse Côte Sud et Nord route Kennedy et retour.Rôle Q-316 34-A-D2 PAUL TREMBLAY TRANSPORT LTEE, 1354.Boul.St-Paul, Chicoutimi, P.Q.Modification relativement au parcours à suivre dans la Cité de Chicotitimi.Parcours à suivre: Remplacer le texte actuel par le suivant: Dans la Cité de Chicoutimi: à partir du pont Dubuc et de là, eut boul.Lamarche, sud rue Morin (arrêt terminus autobus Sa-guenay).est rue Racine, sud rue Bégin, est rue Hôtel-Dieu, sud rue St-Vallier, est rue Jacques-Cartier, sud boul.Talbot, jusqu'au terminus, boul.Talbot Ns 1661.Conditions et restrictions: Les arrêts d'autobus prévus par la Cité de Chicoutimi sur le parcours, constitue des points de débarquements et d'embarquements pour les usagers de St-Honoré et St-David seulement.Rôle Q-317 15332-V-S-l YAMACHICHE TRANSPORT ENRG., (Lucien Bellemare) 811, rue Ste-Anne, Yamachiche, Cté de St-Maurice.Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter a son permis le service additionnel suivant: Transport restreint-longue distance-contrat - A l'aéroport de Dorval, des abattoirs situés dans un rayon de 200 milles dudit aéroport, pour le transport de viande dans des remorques réfrigérées, pour le compte de la compagnie Cofranca Import-Export Inc.five-mile (5) radius.The whole without any prejudices to all rights claimable by the Province of Québec respecting the registration of said chassis.Additional Right: Application for the following additional right : Class of permit: Buss.Service: Special or charter trips from Sts.Anges, Beauce County and St.Sévérin, Beauce County, to all points in the province of Québec.Additional right: Application for the following rights: Class of permit: Bus.Service : (a) Transportation of school children from their homes in the Town of St.Joseph and in the Parish of St.Joseph-des-Erables to the schools in St.Joseph, and return.(ft) Transportation of school children from their homes in St.Jules to the schools in St.Jules and St.Joseph, and return.(c) Transportation of school children from their homes in St.Odilon and parish to the schools in St.Odilon and St.Joseph, and return.(d) Transportation of school children residing in the Town of P*, Joseph and in the Parishes of S*~.A.igC-, Frampton, St.Odilon, St.Jules, St.Sévérin.Tring-Jonction, St.Frédéric, Vallée Jonction, who transfer in the Town of St.Joseph (at the schools) and who attend schools in Beauceville and St.Georges, and return.(e) Transportation of school children from the Town of St.Joseph and Parish at lunch time from the schools in the Town of St.Joseph to ineir homes located in the Town of St.Joseph and Parish, South and North, Côte Kennedy road and return.Modification of the route to follow in the City of Chicoutimi.Route: Replace the existing text by the following: In the City of Chicoutimi: from Dubuc bridge and thence Lamarche Blvd.East, Morin Street South (stop at Saguenay Bus terminal), Racine Street East, Begin Street South, Hôtel-Dieu Street East, St.Vallier Street South, Jacques Cartier Street East, Talbot blvd.South, as far as the terminal at 1561 Talbot Blvd.Conditions and restrictions: The bus stops provided for by the City of Chicoutimi along the route are points for embarking and letting down passengers from St.Honoré and St.David only.Modification of permit.The applicant requests authorization to add the following additional service to its permit: Restricted trucking - long distance - contract - To Dorval airport from the slaughterhouses located within a radius of 200 miles from said airport, for the transportation of of meat in refrigerated trailers, on behalf of Cofranca Import-Export Inc. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1973, 105' année, n' U 6413 Rôle Q-318 1635-A-D2 LES AUTOBUS TREMBLAY & TREMBLAY INC., 1354, Boul.St-Paul, Chicoutimi, Québec.Rôle Q-319 15251-V-D-2 PHILIPPE RICHARD LTEE, St-Pascal, Cté Kamouraska.Rôle Q-320 15251-V-D-3 PHILIPPE RICHARD LTEE, St-Pascal, Cté Kamouraska, Rôle Q-322 197-N D.2 ASSOCIATION DES BATELIERS DE PERCE, Percé, Comté de Gaspé.Modification relativement au parcours il suivre dans la Cité de Chicoutimi.Parcours à suivre: Remplacer le texte actuel par le suivant: Dans la Cité de Chicoutimi: fi partir du pont Dubuc et de la, est boul.Lamarche -sud rue Morin (arrêt terminus autobus Sa-guenay), est rue Racine, sud rue Bégin, est rue Hôtel-Dieu, sud rue St-Vallier, est rue Jacques-Cartier, sud boul, Talbot jusqu'au terminus, boul.Talbot au No 1561.Conditions et restrictions: Les arrêts d'autobus prévus par la Cité de Chicoutimi sur le parcours constituent des points de débarquements et d'embarquements pour les usagers de St-Fulgence et de là, Côte-Nord seulement.Modification de permis.La partie requérante désire ajouter :\\ son permis le service suivant: Transport restreint-longue distance-route restreinte - De la frontière Ontario-Québec.(Port d'entrée: Pivière-Beaudette) a Québec et à tous les endroits des districts électoraux-provinciaux de Lotbinière.Beauce.Dorchester.Lévis, Bellechasse, Montmagny.L'Islet.Kamouraska.Rivière-du-Loup.Témiscouata.Rimouski.Matane.Matapédia et Bonaven-ture, et retour, pour le transport en sacs et en vrac avec équipement spécialisé, de grain, tourteau de soya et autres produits utilisés dans l'alimentation des animaux, pour le public en général.Points d'origine: Prescott, Toronto.Hamilton, Chatham et Peterborough.Ont.Restriction : Ce service sera opéré conjointement, avec un permis connexe de l'Ontario Highway Transport Board, dont copie devra être déposée su dossier.Modification de permis.La partie requérante désire ajouter à son permis le service suivant : Transport restreint-longue distance-route restreinte - De la frontière Etats-Unis-Québec (Port d'entrée: Philipsburg) à Québec et a tous les endroits des districts électoraux-provinciaux de Lotbinière, Beauce.Dorchester, Lévis, Bellechasse, Montmagny, L'Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Rimouski, Matane, Matapédia et Bonaven-ture, pour le transport en sacs et en vrac avec équipement spécialisé, de grain, tourteau de soya et autres produits utilisés dans l'alimentation des animaux, pour le public en général.Point d'origine: Swsnton, Vermont, E.L.Restriction: Ce service sera opéré conjointement avec un permis connexe de l'Interstate Commerce Commission, dont copie devra être déposée au dossier.Changement de sociétaire._ L'Association qui est formé des sociétaires suivants: Arthur Dorion, Mervin Cnhill, Rodolphe Simoneau.James Méthot, Rodolp-phe Méthot.Marcel Donahue.Raoul For-tunat Bourget.Emile Méthot, Louis R.Brochet: _ , .,.¦ demande à la Commission d autoriser le changement du sociétaire Emile Méthot pour être remplacé par M.Leopold Beaudin.Modification of the route to follow in the City of Chicoutimi.Route: Replace the existing text by the following: In the City of Chicoutimi: from Dubuc bridge and thence Lamarche Blvd.East, Morin Street South (stop at Saguenay Bus terminal).Racine Street East, Begin Street South, Hôtel Dieu Street East, St.Vallier Street South, Jacques Cartier Street East, Talbot Blvd.South, as far as the terminal at 1661 Talbot Blvd.Conditions and restrictions: The bus stops provided for by the City of Chicoutimi along the route are points for embarking and letting down passengers from St.Fulgence and thence Côte-Nord only.Modification of permit.The applicant wishes to add the following service to its permit: Restricted trucking - long distance - restricted route - From the Québec-Ontario border (Port of entry Rivière-Beaudette) to Québec and to all points in the provincial electoral districts of Lotbinière, Beauce, Dorchester, Levis, Bellechasse, Montmagny, l'lslet, Kamouraska, Rivière du Loup, Témiscouata, Rimouski, Matane, Matapédia and Bona-venture, and return, for the transportation, in bags and in bulk with special equipment, of grain, soya cakes and other products used for animals consumption, for the public in general.Originating points: Prescott, Toronto, Hamilton, Chatham, and Peterborough, Ont.Restriction : This service shall be operated jointly with a related permit issued by the Ontario Highway Transport Board, a copy of which shall be'filed for the record.Modification of permit.The applicant wishes to add the following service to its permit: Restricted trucking - long distance - restricted route - From the Québec-U.S.border (Port of entry.Philipsburg) to Québec and all points in the provincial electoral districts of Lotbinière, Beauce.Dorchester, Levis, Bellechasse.Montmagny, L'Islet, Kamouraska, Rivière.du-Loup, Témiscouata, Rimouski, Matane, Matapédia and Bonaventure, for the transportation, in bags and in bulk with special equipment, of grain, soya cakes and other products used for animal consumption, for the public in general.Originating points: Swanton, Vermont, U.8.Restriction : This service shall be operated jointly with a related permit issued by the Interstate Commerce Commission, copy of which shall be filed for the record.Change of stock holder.The Association which includes the following stock holders: Arthur Dorion, Mervin Cahill, Rodolphe Simoneau, James Méthot, Rodolphe Méthot, Marcel Donahue, Raoul Fortunat Bourget, Emile Méthot.Louis R.Brochet.requests from the Commission the authorization to replace Emile Méthot, stock holder, by Mr.Leopold Beaudin. 6414 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Rôle M-393 4552-V CHOUINARD & FRERE LTÉE, 8325, rue Pascal-Gagnon.St-Léonard.Que.Rôle M-394 23407-V MARIUS NOEL, 3*55.rue Paré.^'-Hubert.Cté Chambly, P.Q.Rôle M-395 13963-V D-l SPEEDWAY EXPRESS LIMITED, 20, boulevard Marie-Victorin, Boucherville, P.Q.Demande de modification de taux.Par heure Pick up $10.00 Tracteurs $11.25 Tracteurs 10 roues $12.00 sur demande Temps-demi du chauffeur après 8 heures par jour.Service de Highway ?0.50 nu mille parcouru aller-retour.Demande de permis de remorquage (haulaway) -Classe: Transport par remorquage (haulaway) seulement - contrat -Service: Le détenteur appelé voilurier-reinorqueur demande l'autorisation de remorquer, avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques vides ou remplies du voiturier-roulier Speedway Express Limited, dans les cadres du permis No 13963-V, selon la clause a, de ce dernier et pour son compte.Modification de permis de courtier en transport (haulaway) -Classe: Courtier en transport pour utiliser un service de transport par remorquage (haulaway) - Service: Service de courtier en transport pour le transport de marchandises autorisé par son permis de voiturier-roulier No 13903-V, selon la clause a.en utilisant le service de remorquage de monsieur Marius Noël appelé voiturier-remorqueur.Request for rate modification.Per hour Pickup S10.00 Tractors SI 1.25 Ten-wheel tractors 812.00 on request Time and a half for the driver for over 8 hours per day.Highway service 80.50 per mile travelled, round trip.Request for a permit of haulaway service - Class: Haulaway transport only - contract -Service : The holder, called haulaway operator, requests the authorization to haul with his duly registered tractors, empty or loaded trailers belonging to carrier Speedway Express Limited, in conformity with clause a of permit No.13963-V of the latter and on its behalf.Modification of haulaway transport broker's permit -Class: Transport broker utilizing a haulaway transportation service -Service: Transport broker service for the transportation of goods authorized by its carrier permit No.13963-V, in conformity with clause a, utilizing the haulaway service of Mr.Marius Noël, called haulaway operator.Rôle M-396 SYLVESTRE TRANSPORT INC., 105.rue Michaud.Laval des Rapides (Laval).Que.Modification.Permis h contrat: Pour le transport de marchandises, pour le compte de Transport Eddy Veilleux Ltée, permis No 17417-V, selon les clauses a, b, c, d, e, f, g, h et t.n) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat.a) De tous points situés dans les districts électoraux-provinciaux d'Ahitibi-Est, d'Abiti-bi-Ouest à Montréal et à tous les endroits situés dans un rayon de 125 milles, via routes 59.58 et 11, pour le transport de bois blanchi, pour le compte de Le Syndicat de Normandin Lumber Ltée, Paradis & Fils Ltée, Léonard EUen Inc.et sa compagnie subsidiaire G.A.Grier & Song Ltd.b) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - b) De tous points situés dans les districts électoraux-provinciaux d'Abitibi-Est, d'Abi-tibi-Ouest, aux frontières Québec-Ontario, pour le transport de bois blanchi, pour le compte de Le Syndicat de Normandin-Lum-ber Ltée.Léonard Ellen Inc.c) Transport restreint - longue distance -route restreinte - c) De tous les points situés dans les districts électoraux-provinciaux de Roberval, Lac St-Jean, Chicoutimi, Jonquicre.Dubuc, Matapédia, Gaspé-Nord, Gnspé-Sud.Bona-venture, à Québec et à tous les endroits situés dans un rayon de 50 milles de cette ville, à l'exception des localités du district électoral-provincial de Montmagny, ainsi qu'à Montréal et à tous les endroits situés dans un rayon de 125 milles de cet endroit, pour le transport de bois blanchi.d) Transport, restreint - longue distance -route restreinte - Modification.Contract permit : For the transportation of goods, on behalf of Transport Éddy Veilleux Ltée, permit No.17417-V, according to clauses a, b, c, d, e,/, g, h and i.(a) Restricted truking - long distance -restricted route - contract - (a) From all points located in the provincial electoral Districts of Abitibi-East, Abiti-bi-West to Montreal and to all points located within a radius of 125 miles, via highways 59, 58 and 11, for the transportation of bleached wood on behalf of Le Syndicat de Normandin Lumber Ltée, Paradis & Fils Ltée, Léonard Ellen Inc.and its subsidiary company G.A.Grier & Sons Ltd.(b) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (6) From all points located in the provincial electoral Districts of Abitibi-East, Abiti-bi-West to the Québec-Ontario border, for the transpotation of bleached wood, on behalf of Le Syndicat de Normandin Lumber Ltée and Léonard Ellen Inc.(c) Restricted trucking - long distance -restricted route - (c) From all points located in the provincial electoral Districts of Roberval, Lake St.John, Chicoutimi, Jonquière, Dubuc, Matapédia, Gaspé-North, Gaspé-South, Bo-naventure to Québec City and to all points located within a 50-mile radius from this City, excepting the localities of the provincial electoral District of Montmagny; as well as to Montreal and all points located within a radius of 125 miles from said City, for the transportation of bleached wood.(rf) Restricted trucking - long distance -restricted route - GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n9 U 6415 Rôle M-397 1991-V-D-l ADRIEN MASSE.Coteau du Lac (Vaudreuil-Souianges).Que.d) De tous points situés dans les districts électoraux-provinciaux de Roberval, Lac St-Jean.Chicoutimi, Jonquière, Kénogami, Dubuc.Matapédia.Matane, Gospé-Nord.Gas-pé-Sud et Bonaventure aux frontières Québec-Ontario, pour le transport de bois blanchi.e) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - e) De St-Pamphile, Que aux frontières Québec-Ontario (tous ports d'entrée) destination: tous les points de l'Ontario, pour le transport de bois blanchi, pour le compte de Les Matériaux Blanchet Inc.Restriction: Le service autorisé par les clauses b, d et e de ce permis ne sera opéré que conjointement avec le permis extra provincial X-1712 émis par l'Ontario Highway Transport Board et daté du 17 avril 1970.fS Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - /) De Ville Degelis (Ste-Rose-du-Dêgelisï aux frontières Québec-Ontario, ports d'entrée: Rivière Beaudette et Pointe-Fortune.Destination: Ottawa et Toronto, pour le transport de bois blanchi pour le compte de Le Syndicat de Nornundin Lumber Ltée.Restriction: Le service précité ne 'era oi>éré que conjointement avec un permis complémentaire a être obtenu de l'Ontario Highway Trans-port Board et dont copie devra être déposée ft la Commission d'ici le 1er mai 1973.g) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrater) De tous points situé» duns les districts électoraux-provinciaux d'Abitibi-Est, et d'Abitibi-Ouest aux frontières Québec-Etats Unis, pour le transport de bois blanchi.]>our le compte de Le Syndicat de Normandin Lumber Ltée et de Léonard Ellen Inc.Transport restreint - longue distance -route restreinte - h) De tous points situés dans les districts électoraux-provinciaux de Roberval, Lac St-Jean, Chicoutimi.Jonquière.Kénogami.Dubuc.Matapédia, Matane.Gaspé-Nord.GasDé-Sud et Bonavenfjre, aux frontières Québec-Etats-Unis, pour le transport de bois blanchi.Restrictions Re/clauses g et h.Les services autorisés par le» clauses g et h de ce permis ne seront opérés que conjointement avec le permis de ('Interstate Commerce Commission.No MC-130598, daté du 24 novembre 1972.0 Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat \u2022 i) De tous les endroits situés dans les comtésd'Abitibi-Est.Abitihi-Ouest et Rouyn-Norandaa Montréal et tous les endroits situés dans un rayon de 50 milles de Mont réal.pour le transport de bois plané pour le compte de Bock & Tétrenu Ltée.Cession de la propriété du système de transport (vente).Monsieur Adrien Masse demande l'autorisation de céder à Maheu Transport Inc.Saint - Stanislas- de - Kostkn (Beauharnois).Que.20590-V.la propriété du système de transport suivant: Permis No 1991-V.Transport général De Rivière-Beaudctte à Montréal (via route No 2) et points intermédiaires, aussi St-CIet, Les Cèdres, St-Lazarc, Pont-Châ- (d) From all points located in the provincial electoral Districts of Roberval, Lake St.John.Chicoutimi, Jonquière, Kénogami, Dubuc, Matapédia.Matane, Gaspé-North, Gaspé-South and Bonaventure, to the Québec-Ontario border, for the transportation of bleached wood.(e) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (r) From St.Pamphile (Que.) to the Québec-Ontario border (all ports of entry); destination: all points in Ontario, for the transportation of bleached wood, on behalf of Les Matériaux Blanchet Inc.Restriction: The service authorized by clauses b, d and r of this permit shall be operated only with the extra-provincial permit No.X-1712 issued by the Ontario Highway Transport Board, dated April 17.1970.(/) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (/) From Town of Dêgelis (Ste-Rose-du-Dégelîs) to the Québec-Ontario border, ports of entry: Rivière-Beaudette and Pointe-Fortune.Destination: Ottawa and Toronto, for the transportation of bleached wood on behalf of Le Syndicat de Normandin Lumber Ltée.Restriction: The foregoing sen-ice shall only be operated with a complementary permit to be issued by the Ontario Highway Transport Board, a copy of which shall be filed with the Commission not later than May 1, 1973.(g) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - ig) From all points located in the provincial electoral Districts of Abitibi-East and Abitibi-West to the Québec-United States border, for the transportation of bleached wood on behalf of Le Syndicat de Normandin Lumber Ltée and of Léonard Ellen Inc.(h) Restricted trucking - long distance -restricted route - (h) From all points located in the provincial electoral Districts of Roberval, Lake St.John, Chicoutimi, Jonquière, Kénogami.Dubuc, Matapédia.Matane, Gaspé-North, Gaspé-South and Bonaventure.to the Quebec-United States border, for the transportation of bleached wood.Restriction Re/clauses :/ and A.The services authorized under clauses g and A of this permit shall be operated only in conjunction with a related permit from the Interstate Commerce Commission, No.MC-130698.dated November 24, 1972.(i) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (i) From all points located in the Counties of Abitibi-East.Abitibi-West and Rouyn-No-randa to Montreal and all points located within a radius of 50 miles from Montreal, for the transportation of plaued wood, on behalf of Bock & Tétreau Ltée.Transfer of ownership of a transport sen-ice 'sale).Mr.Adrien Masse requests authorization to transfer to Maheu Transport Inc.St.Stani.slas-de-Kostka (Beauharnois), P.Q.(20590-V), the ownership of the following transport sen-ice: Permit No.1991-V.General trucking From Rivière-Beaudette to Montreal (via Highway No.2) and intermediate localities, including St.Clet, Les Cèdres, St.Lazare, 6410 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 3, 1973, Vol.105, No.U Rôle M-398 23404-V D-l PIERRE-ANDRE Il MU IX.2806, rue Rouen, Montréal 134, P.Q.Rôle M-399 7737-V D-l BELLECHASSE TRANSPORT INC., 3600.boulevard Wilfrid Hamel, Québec.P.Q.Rôle M-400 17513-V-D-l ST-AMOUR TRANSPORT LTÊE.4014, rue Evelyn, Verdun.Ile de Montréal, Que.Rôle M \u2014401 23310-V-D-l MELVILLE HILL, R.R.No.4, Hemmingford, Que.Rôle M-*02 1818-V D-l THIFFAULT TRANSPORT INC., 7961.Boulevard St-Michel, Montréal 455, P.Q.teau.St-Polycarpe.St-Télesphore.Dalhou-aie, De Beau jeu, Ste-Marthe, Coteau Station et Ste-Justine.et retour.Demande de permis de remorquage (haulaway).Classe: Transport par remorquage (haulawa> ) seulement - contrat -Service: Le détenteur appelé voituner-remorqueur demande l'autorisation de remorquer, avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques vides ou remplies du voiturier-roulier Bellechasse Transport Inc., dans les cadres du permis No 7737-V, selon les clauses a ô z et aa à et, de ce dernier et pour son compte.Modification de permis de courtier en transport.Classe: Courtier en transport pour utiliser un service de transport par remorquage (haulaway) - Service: Service de courtier en transport pour le transport de marchandises autorisé par son vr: rni de voiturier-roulier No 7737-V.selon les clauses a a z et an à ee, en utilisant le service de remorquage de M.Pierre-André Lemieux appelé voiturier-remorqueur.Modification de clause: La partie requérante demande qu'a la clause suivante: Transport restreint - service local - contrat - Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite ville, pour le transport de marchandises, pour le compte d'Eastem Co.Ltd.et Rohm & Hass Co.Ltd.soit ajouté l'expéditeur suivant: Dobi Distribution Ltd.Nouvelle demande: Le requérant demande à la Commission l'autorisation d'exploiter le service de transport suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - De Huntingdon a Athelstan.Hemmingford, Lacolle, Clarenceville, Blackpool et les localités intermédiaires, via les routes 52 et 9.pour le transport de journaux et de revues, pour le compte de Suggars News Distributors.Changement de contrôle du système de transport (vente d'actions).Dame Georgette G.Thiffault.Monsieur Paul-Emile Thiffault e*.Monsieur Ernest Baril ont vendu à M.Jean-Jacque* Prud'homme.M.Gérard Prud'homme et Dame Marie-Rose Roy, les 48 actions communes qu'ils détiennent dans la compagnie mise en cause.Ils demandent a la Commission de ce faire, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi des transports.Distribution actuelle: Georgette G.Thiffault 46 actions communes Paul Eddie Thiffault 1 action commune Ernest Baril 1 action commune Nouvelle Distribution: Jean-Jacques Prud'homme 46 actions communes Pont-Château.St.Polycarpe.St.Télesphore, Dalhousie.DeBeaujeu.Ste.Marthe, Coteau Station and Stc.Justine, and return.Application for a haulaway operator permit.Class: Haulaway transportation only - contract -Service : The permit-holder, designated as haulaway operator, requests authorization to haul, with his duly-registered tractors, the trailers (empty or loaded) belonging to carrier Bellechasse Transport Inc., according to clauses a to t and aa to re of the tatter's permit No.7737-V and on behalf of said carrier.Modification of transport broker permit.Class: Transport broker to utilize a haulaway transportation service.Service: Transport broker service for the transportation of goods authorized by clauses a to z and aa to ee of its carrier's permit No.7737-V, utilizing the haulaway service provided by Mr.Pierre-André Leniieux, designated as hanlaway operator.Modification of clause: The applicant requests that an addition be made to the following clause: Restricted trucking - local service - contract - Montreal and all points located within a distance of not more than five (5) miles from the limits of said City, for the transportation of goods, on behalf of Eastern Co.Ltd.and Rohm & Hass Co.Ltd.to include the following shipper: Dobi Distribution Ltd.New application: The Applicant asks the authorization of the Commission to give the following service of transport: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract.From Huntingdon to Athelstan, Hemmingford.Lacolle, Clarenceville, Blackpool and intermediate points via Routes 52 and 9, for the transportation of papers and magazines, for the account of Suggars News Distributors.Change of control in a transport service (sale of shares).Mrs.Georgette G.Thiffault.Mr.Paul-Emils Thiffault and Mr.Ernest Baril have sold to Mr.Jean-Jacques Prud'homme, Mr.Gérard Prud'homme and Mrs.Marie-Rose Roy.the 4S common shares they hold in the company mise en cause.Authorization to do so is requested from the Commission, pursuant to the provisions of section 39 of the Transport Act.Present allotment: Georgette G.Thiffault 46 common shares Paul Eddie Thiffault 1 common share Ernest Baril 1 common share New allotment: Jean-Jacques Prud'homme 46 common shares GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1973.105' année, //° U 6417 Rôle M -403 619-V-D-l UNIC TRANSPORT LTÉE, 39, 1ère Avenue, Delson (Chûteauguay), Que.Rôle M -104 5334-V-D SOULANCES CARTAGE * EQUIPMENT CO.LTD., 7150, rue Hochelaga, Montréal 427.Que.Kôle M-405 7141-V D-l L.THIBODEAU TRANSPORT INC., 228, 2ième Avenue, Portneuf, Cté Portneuf, P.Q.Rôle M-406 1714-V D-3 CATIEN TRANSPORT INC.St-Bernard de Lacolle, Cté St-Jean, P.Q.Rôle M-407 23386-V D-l LEO FISET.Cap Santé, Cté Portneuf, P.Q.Rôle M-408 4651-V D-l CABANO TRANSPORT LIMITÉE, Caae Postale 404, Rivière-du-Loup, P.Q.Marie-Rose Roy 1 action commune Gérard Prud'homme 1 action commune Demande de modification de haulaway.Transport par remorquage (haulaway) seulement - contrat- Le détenteur appelé voiturier-remorqueur demande l'autorisation de remorquer, avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques vides ou remplies du voiturier-roulier Soulanges Cartage & Equipment Co.Ltd., dans les cadres du permis No 5334-V, selon les clauses a h k inclusivement, de ce dernier et pour son compte.Demande de modification de courtier.Courtier en transport pour utiliser un service de transport pour remorquage (haulaway) - Service de courtier en transport pour le transport de marchandises autorisé par son permis de voiturier-roulier No 5334-V, selon les clauses n à k inclusivement, en utilisant le service de remorquage de Unie Transport Ltée appelé voiturier-remorqueur.Modification de permis de courtier.Classe: Courtier en transport pour utiliser un service de transport par remorquage (haulaway) - Service: Service de courtier eu transport pour le transport de marchandises autorisé par son permis de voiturier-roulier No 7141-V, selon les clauses a à n inclusivement, en utilisant le service de remorquage de Gatien Transport Inc.appelé voiturier-remorqueur.Modification de permis de remorquage.Classe: Transport par remorquage (haulaway) seulement - contrat -Service: Le détenteur appelé voiturier-remorqueur demande l'autorisation de remorquer, avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques vides ou remplies du voiturier-roulier L.Thibodeau Transport Inc., dans les cadres du permis No 7141-V, selon les clauses a a n inclusivement, de ce dernier et pour son compte.Modification de permis de remorquage.Classe: Transport par remorquage (haulaway) seulement - contrat -Service: Le détenteur appelé voiturier-remorqueur demande l'autorisation de remorquer avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques vides ou remplies du voiturier-roulier Cabano Transport Limitée dans les cadres du permis No 4651-V, selon les clauses c, d, r.f, g, et h, de ce dernier et pour son compte.Modification de permis de courtier -Classe : Courtier en transport pour utiliser un service de transport par remorquage (haulaway).Service: Service de courtier en transport, pour le transport de marchandises autorisé par son permis de voiturier-roulier No 4651-V, selon les clauses c, d, e,f, g, et h, en utilisant le service de remorquage de Léo Fiset appelé voiturier-remorqueur.Marie-Rose Roy 1 common share Gérard Prud'homme 1 common share Application for modification of haulaway transport.Haulaway transportation only - contract -The permit-holder, designated as haulaway operator, requests authorization to hau), with its duly-registered tractors, the trailers (empty or loaded) belonging to carrier Soulanges Cartage & Equipment Co.Ltd., according to clauses a to k inclusive of the latter's permit No.5334-V and on behalf of said carried.Application for modification (broker).Transport broker to utilize a haulaway ( raits) )ort at ion service.Transport broker service for the transportation of goods authorized by clauses a to k inclusive of its carrier's permit No.5334-V, utilizing the haulaway service provided by Unie Transport Ltée, designated as haulaway oi>erator.Modification of broker's permit.Class: Transport broker to utilize a haulaway transportation service - Service-Transport broker service for the transportation of goods authorized by clauses a to n inclusive of its carrier's permit No.7141-V.utilizing the haulaway service provided by Gatien Transport Inc., designated as haulaway operator.Modification of haulaway permit.Class: Haulaway transportation only - contract -Service : The permit-holder, designated as haulaway operator, requests authorization to haul, with its duly-registered tractors, the trailers (empty or loaded) belonging to carrier L.Thibodeau Transport Inc.according to clauses a to n inclusive of the latter's permit No.7141-V and on behalf of said carrier.Modification of haulaway permit.Class: Haulaway transportation only - contract -Service: The permit holder designated as haulaway operator requests authorization to haul with his duly registered tractors empty or loaded trailers owned by Cabano Transport Limitée, carrier, pursuant to clauses c, d, e, f, g and h of the latter's permit No.4651-V and on its behalf.Modification of broker permit - Class: Transport broker to utilize a haulaway transportation service.Service: Transport broker service, for the transportation of goods authorized by its carrier permit No.4651-V, pursuant to clauses c, d, e, f.g and h, utilizing the haulaway service of Léo Fiset designated as haulaway operator. 641H QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol 105, No.U Rôle M-409 6793-V D-2 BRAZEAU TRANSPORT INC., 3.80.rue Burke.Rouyn (Rouyn-Noranda).Que.Rôle M-410 23449-V D-l JEAN-MARIE FRENETTE.2490, rue St-Zotique.-Montréal, Que.Rôle M-411 22478-V-D-l J.ANDRE BERGERON.PB.278 - New Hoscosite, Matagami (Abitibi-Est), Que.Rôle M -412 23120-V D-l BOURQUE, RODERICK, Canning, King's County.Nova Scotia.Rôle M-413 23I2I-V D-l FLOYD, RUSSEL, 379, Beacons Field Crescent West.8t-John.N.B.Demande de modification de courtier.Courtier en transport pour utiliser un service de transport par remorquage (haulaway\") - Service de courtier en transport pour le transport de marchandises autorisé par son permis de voiturier-roulier No 6793-V.selon les clauses c à z, aa à zz, aaa à ///, en utilisant le service de remorquage de Jean-Marie Fre-nette appelé voiturier-remorqueur.Nouvelle demande de (haulaway).Transport par remorquage (haulaway) seulement - contrat - Le détenteur appelé voiturier-remorqueur demande l'autorisation de remorquer, avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques vides ou remplies du voiturier-roulier Brazeau Transport Inc., dans les cadres du permis 6793-V.selon les clauses c k z.aa h zz, aaa à///, de ce dernier et pour son compte.Cession de la propriété du système de transport (vente).M.J.André Bergeron demande l'autorisation de céder à: Del Transport Ltée, 385.Ave Richelieu.McMasterville (Ver-chères).Que.21339-V.la propriété du système de transport suivant: Permis No 22478-V.Transport restreint - service local Matagami et tous le* endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport de dynamite, explosifs et agent de saut age.Restriction: Cette autorisation est subordonnée, pour le transport de quantité excédant 4.000 livres, à l'obligation et au maintien en vigueur d'un permis a être émis par le Ministère de l'Energie des Mines et des Ressources.« Division des Explosifs ».Modification de clause.Le requérant détient un permis qui se lit comme suit: Transport par remorquage seulement -contrat - Le requérant appelé voiturier-remorqueur est autorisé à remorquer, avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques vides ou remplies appartenant au voiturier-roulier Maritime Ontario Freight Lines Ltd., détenteur du permis no 19102-V, conformément à la clause dudit permis.Le requérant souhaite modifier ledit permis afin qu'il se lise à l'avenir comme suit: Clause: Transport restreint - longue distance route restreinte - contrat - en transit.Service: De la frontière Québec-Ontario (tou« les |k>rts d'entrée) à la frontière Québec-Nouveau Brunswick (tous les ports de sortie) et retour, pour le transport de marchandises Cour le compte de Maritime Ontario Freight ines Ltd., détenteur du permis no 19102-V, subordonné à toutes les restrictions se rattachant au permis de ce dernier.Modification de clause.Le requérant détient un permis qui se lit comme suit: Transport par remorquage seulement -contrat - Le requérant appelé voiturier-remorqueur est autorisé a remorquer, avec ses tracteurs dûment enregistrés.les remorques vides ou remplies appartenant au voiturier-roulier Request for modification of a broker permit.Transport broker to utilize a haulaway transportation service.Transport broker service for the transportation of goods authorized by its carrier permit No.6793-V, pursuant to clauses c to z, aa to zz, aaa to///, utilizing the haulaway service of Jean-Marie Frenette designated as haulaway operator.New application for a haulaway permit.Haulaway transportation only - contract - The permit holder designated as haulaway operator requests authorization to haul, with its duly registered tractors, empty or loaded trailers of Brazeau Transport Inc., carrier, pursuant to clauses e to z.aa to zz, aaa tofff, of the latter's permit No.6793-V.and on its behalf.Transfer of ownership of transport service Mr.J.André Bergeron requests authorization to transfer to: Del Transport Ltée, 385 Richelieu Avenue, McMasterville (Ver-chères), Que.21339-V.ownership of the following transport service: Permit No.22478-V.Restricted trucking - local service - Matagami and all points located within a distance not exceeding 5 miles from the limits of said town, for the transportation of dynamite, explosives and detonating products.Restriction: This authorization is subject, for the transportation of loads exceeding 4.000 pounds, to the obligation of holding and maintaining a permit to be issued by the Department of Energy, Mines, and Ressources, Explosives Division.Amendment of clause.The applicant whose permit reads as follows: Haulaway transportation only - contract - The permit holder designated as a haulaway operator is authorized to haul, with his tractors duly registered, empty or loaded trailers belonging to the highway carrier Maritime Ontario Freight Lines Ltd., No.19102-V.in conjunction with the clause of the said permit.Wishes to modify the said permit so that, in future, it shall read as follows: Class: Restricted trucking - long distance - restricted route - contrat - in transit.Service : From the Québec-Ontario border (all ports of entry) to the Québec-New Brunswick border (all ports of exit) and return, for the transportation of goods for the account of Maritime Ontario Freight Lines Ltd., permit No.19102-V, subject to all restrictions attached to the latter permit.Amendment of clause.The applicant whose permit reads as follows: Haulaway transportation only - contract - The permit holder designated as a haulaway operator is authorized to haul, with his tractors duly registered, empty or loaded trailers belonging to the highway carrier GAZETTE 0F1CÏELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 106' année, n° U 6419 Rôle M-414 23123-V D-l WOODSIDE, CHARLIE, 170, Union Street, St.Stephen, N.B.Rôle M-415 23122-V D-l FLOYD, WINDSOR, 104, Rayland Street, St-John.N.B.Rôle M-416 21162-V-D-l LUSSIER TRANSPORT, (Auguste Lussier operating under the name of) P.O.Box 131, St-Alban, Vermont 05478, U.S.Maritime Ontario Freight Lines Ltd., détenteur du permis no 19102-V.conformément à la clause dudit permis.Le requérant souhaite modifier ledit permis afin qu'il se lise à l'avenir comme suit: Classe: Transport restreint-longue distance-route restreinte-contrat-en transit.Service: De la frontière Québec-Ontario (tous les ports d'entrée) à la frontière Québec-Nouveau Brunswick, (tous les ports de sortie) et retour, pour le transport de marchandises pour le compte de Maritime Ontario Freight Lines Ltd., détenteur du permis no 19102-V.subordonné à toutes les restrictions se rattachant au permis de de dernier.Modification de clause.Le requérant détient un permis qui se lit comme suit: Transport par remorquage seulement -contrat - Le requérant appelé voiturier-remorqueur est autorisé à remorquer, avec ses tracteurs dûment enregistrés, tes remorques vides ou remplies appartenant au voiturier-roulier Maritime Ontario Freight Lines Ltd., détenteur du permis no 19102-V, conformément à la clause dudit permis.Le requérant souhaite modifier ledit permis afin qu'il se lise à l'avenir comme suit: Classe: Transport restreint-longue distance-route restreinte-contrat-en transit.Service: De la frontière Québec-Ontario (tous les ports d'entrée) à la frontière Québec-Nouveau Brunswick (tous les ports de sortie) et retour, pour le transport de marchandises pour le compte de Maritime Ontario Freight Lines Ltd., détenteur du permis no 19102-V, subordonné à toutes les restrictions se rattachant au permis de ce dernier.Le requérant détient un permis qui se lit comme suit: Transport par remorquage seulement -contrat - Le requérant appelé voiturier-remorqueur est autorisé à remorquer, avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques vides ou remplies appartenant au voiturier-roulier Maritime Ontario Freight Lines Ltd., détenteur du permis no 19102-V, conformément a la clause dudit permis.Le requérant souhaite modifier ledit permis afin qu'il se lise à l'avenir comme suit: Classe: Transport restreint-longue distance-route restreinte-contrat-en transit.Service: De la frontière Québec-Ontario (tous les ports d'entrée) à la frontière Québec-Nouveau Brunswick (tous les ports de sortie) et retour, pour le transport de marchandises pour le compte de Maritime Ontario Freight Lines Ltd., détenteur du permis no 19102-V, subordonné à toutes les restrictions se rattachant au permis de ce dernier.Modification de la clause suivante: Transport restreint-longue dis tance-route restreinte.De Rivière-du-Loup à la frontière Québec-Etats-Unis (tous les ports d'entrée) pour le Maritime Ontario Freight Lines Ltd., No.19102-V, in conjunction with the clause of said permit.Wishes to modify the said permit so that, in future, it shall read as follows: Class: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - in transit.Service: From the Québec-Ontario border (all port* of entry) to the Québec-New Brunswick border (all ports of exit) and return, for the transportation of goods for the account of Maritime Ontario Freight Lines Ltd., peimit No.19102-V.subject to all restrictions attached to the latter permit.Amendment of clause.The applicant whose permit reads as follows: Haulaway transportation only - contract - The permit holder designated as a haulaway operator is authorized to haul, with his tractors duly registered, empty or loaded trailers belonging to the highway carrier Maritime Ontario Freight Lines Ltd., No.19102-V, in conjunction with the clause of the said permit.Wishes to modify the said permit so that, in future, it shall read as follows: Class: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - in transit.Service: From the Québec-Ontario border (all ports of entry) to the Québec-New Brunswick border (all ports of exit) and return, for the transportation of goods for the account of Maritime Ontario Freight Lines Ltd., permit No.19102-V, subject to all restrictions attached to the latter permit.The applicant whose permit reads as follows: Haulaway transportation only - contract - The permit holder designated as a haulaway operator is authorized to haul, with his tractors duly registered, empty or loaded trailers belonging to the highway carrier Maritime Ontario Freight Lines Ltd., No.19102-V, in conjunction with the clause of the said permit.Wishes to modify the said permit so that, in future, it shall read as follows: Class: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - in transit.Service: From the Quebec-Ontario border (all ports of entry) to the Québec-New Brunswick border (all ports of exit) and return, for the transportation of goods for the account of Maritime Ontario Freight Lines Ltd., permit No.19102-V, subject to all restrictions attached to the latter permit.Modification of the following clause: The applicant asks that the following clause : Restricted trucking - long distance - restricted route - From Rivière-du-Loup to the Québec~U.S.border (all ports of entry) for the carriage 6420 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Rôle M-417 13930-V-D-l ROGER ROCHON, 101, boul.St-Canut, Saint-Canut, (Deux-Montagnes), Quo.Rôle M-418 14385-V D-l TF 14628-V D-l TF 10831-V D-l TF AUTOMOBILE TRANSPORT LIMITED, CHARLTON TRANSPORT (QUEBEC) LTD., McCALLUM TRANSPORT (QUEBEC) LTD., St-Laurent, Monast, Des-meulea.Walters & Vallières, Me Renault St-Laurent, Edifice La Laurentienne, Suite 609, 500, est Grande-Allée, Québec.G1R2J7.Procureur.Rôle M-419 32-N D-I TF CLARKE STEAMSHIP CO.LTEE, B.P.730, Station « B ¦», Montréal, P.Q.Rôle M-420 D-I-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS.N.555, Dixon Road, Rexdale, Ontario.transport de tourbe, à destination des états suivants: Nouvelle Angleterre, New York, New Jersey, Pennsylvanie.Delaware, Maryland, District de Colombia, Ohio et Virginie, pour le public.Etant donné que les marchandises ci-dessus sont exemptes des règlements stipulés en vertu de la loi sur l'Interstate Commerce Commission, aucun certificat émis par ladite commision n'est requis.Le requérant demande que la clause ci-dessus soit remplacée par la suivante: Transport restreint-longue distance-route restreinte.De tous les points de la province de Québec a la frontière Québec-Etats-Unis (tous les ports d'entrée) pour le transport de tourbe, ladite marchandise étant destinée aux états suivants: Nouvelle Angleterre, Connecticut, New Jersey, New York.Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Ohio.Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Floride pour le public.Les marchandises ci-dessus étant exemptes des règlements stipulés en vertu de la loi sur l'Interstate Commerce Commission.Cession de la propriété du système de transport (suite à demande d'incorporation par la requérante), La partie-requérante demande l'autorisation de la Commission de céder la propriété du système de transport qu'elle exploite à la compagnie Transport R.Rochon Inc.dont elle possède la majorité des actions et dont le siège social sera au même endroit.Demande de fixation de taux et tarifs de transporteurs de véhicules automobiles S.P.V.8 (annule le tarif S.P.V.7) s'appliquant entre les localités situées dans la province de Québec.of peat moss, said merchandise destined to the following states of U.S.: New England, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, District of Columbia, Ohio and Virginia, for the public in general.The above mentioned merchandise being exempt from regulations under the Interstate Commerce Commission Act, no certificate by the said commission is required, be replaced by the following: Restricted trucking - long distance - restricted route - From any points in the Province of Québec to the Québec-U.S.border (all ports of entry:) for the carriage of peat moss, said merchandise destined to following states of U.S., New England, Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Ohio, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, for the public in general.The above mentioned merchandise being exempt from regulations under the Interstate Commerce Commission Act.Transfer of ownership of transport service (following an incorporation request by the applicant).The applicant requests from the Commission the authorization to transfer ownership of the transport service that he operates, to Transport R.Rochon Inc.; the applicant owns the majority of shares in this company and ifs head office shall be located at the same address.Request for fixing the rates and tariffs applicable to motor vehicle carriers S.P.V.8 (cancels tariff S.P.V.7) between various localities in the province of Québec.Demande d'augmentation de tarif de 6% pour la saison d'hiver 1973-1974, tarif No CSS 20-C, pour transport de marchandises générales entre Montréal et Sept-IIes-Port-Cartier et de Québec a Sept-IIes.Request for a 6% tariff increase for the 1973-1974 winter season, tariff No.CSS 20-C, for the transportation of general goods between Montreal and Sept-Ues-Port-Cartier and from Québec to Sept-Ues.Tarif spécial C.T.4048 Ljour les marchandises générales en vertu de la demande de permis de Cowansville Express Inc.Tarif de taux d'urgence Québec-Ontario 2259, C.T.4044, applicable aux déchets ou rebuts de papier et chiffons.Tarif de taux d'urgence Québec-Ontario 2258 C.T.4043, pour les pneus en caoutchouc.Tarif de taux d'urgence Québec-Ontario 2257, C.T.4042 pour le fer et l'acier.Tarif spécial C.T.1533, pour ajuster les taux actuellement applicables à diverses marchandises.Annexe: Special Tariff T.B.Q.4048 on General Merchandise under permit application of Cowansville Express Inc.Québec-Ontario Emergency Rate Tariff 2259, T.B.Q.4044, on Scrap or Waste Paper and Rags.Québec-Ontario Emergency Rate Tariff 2258, T.B.Q.4043, on Rubber Tires.Québec-Ontario Emergency Rate Tariff 2267, T.B.Q.4042, on Iron or Steel.Special Tariff T.B.Q.1533, adjusting existing rates on various commodities. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n° U 6421 Tarif spécial C.T.4045.applicable dans le cas du contrat Dumont Express Ltée pour le compte de la Société des Alcools du Québec.Tarif de taux d'urgence Québec-Ontario 2261 C.T.4047, pour les chauffe-eau.Tarif de taux d'urjence Québec-Ontario 2260, C.T.4046, pour les composés métalliques.Tarif de classe Québec-Ontario 10-E, C.T.1500, addition d'une exception à la règle 140 via MacKinnon Transport Ltd.Tarif de marchandises Québec-Ontario 15-K, C.T.2805, modifié comme suit: Règle 22: Addition des taux applicables à 10,000 lbs et 15.000 lbs à l'articleo, également addition de la remarque suivante: i Le supplément arbitraire sera évalué sur une base du poids affiché ».Règle 23: Addition de la remarque suivante - « Le supplément arbitraire sera évalué sur la base du poids affiché.Poste 660: Correction de l'erreur de frappe concernant le taux applicable a 24.000 lbs de Valleyfield à Amherstburg.Poste 4918: Etablissement du taux applicable aux machines servant à fabriquer des pneus, de Cambridge à Valleyfield.Poste 5185: Etablissement du taux applicable aux viandes pour la consommation animale, de Montréal à Missisaugn.Poste 5225: Annulation du taux applicable aux viandes, de Montréal à Missisauga.Poste 5830: Etablissement de taux applicables aux palettes en bois vides, de Beauharnois (Maple Grove) à Hamilton et Toronto.Poste 7365: Addition du taux applicable a l'amidon, de Montréal a Ottawa.Poste 8618: Etablissement du taux applicable au fibre de polyester, de Hawkesbury a Shawinigan.Tarif de marchandises 32-G Québec-Ontario pour le fer et l'acier C.T.2909 modifié par l'addition aux règles 22 et 23 de la remarque suivante: « Le supplément arbitraire sera évalué sur la base du poids affiché ».Tarif de marchandises en papier Québec-Ontario 40-G.C.T.2910.modifié par l'addition aux règles 22 et 23 de la remarque suivante: « Le supplément arbitraire sera évalué sur la base du poids affiché I.Tarif applicable aux marchandises d'exportation et d'importation Québec-Ontario 45-M.C.T.2808 modifié par l'addition à la règle 22 de la remarque suivante « Le supplément arbitraire sera évalué sur la base du poids affiché ».Tarif concurrentiel Québec-Ontario 71-D.C.T.2926 modifié par l'addition aux règles 35 et 36 de la remarque suivante: « Le supplément arbitraire sera évalué sur la base du poids affiché ».et par addition à la règle 35 des taux arbitraires applicables aux poids de 10,000 Ibs et 15,000 lbs.Tarif applicable aux containers Québec-Ontario 74-A, C.T.3372 modifié par addition à la page 4 des taux applicables entre Montréal et Trenton.Tarif de marchandises Québec-Western Canada 1005-D, C.T.3485, modifié comme suit: Special Tariff T.B.Q.4045 covering contract of Dumont Express Ltée on behalf of La Société des Alcools du Québec.Québec-Ontario Emergency Rate Tariff 2261, T.B.Q.4047, on Water Heaters, Québec-Ontario Emergency Tariff 2260.T.B.Q.4046, on Compounds.Québec-Ontario Class Tariff 10-E, T.B.Q.1500.addition of exception to Rule 140 via MacKinnon Transport Ltd.Québec-Ontario Commodity Tariff 15-K, T.B.Q.2805, amended as follows: Rule 22: 10.000 lb and 15.000 lb rates added to Section a, also addition of note - \"The arbitrary shown will be assessed on the basis of billed weight\".Rule 23: Addition of note - \"The arbitrary shown will be assessed on the basis of billed weight\" Item 660: Correction to typing error in 24,000 lb rate from Valleyfield to Amherstburg.Item 4918: Establishment of rate ou Tire-Making Machinery from Cambridge to Valleyfield.Item 6185: Establishment of rate on Meats, for Animal Consumption, from Montreal to .Missisauga.Item 5226: Cancellation of rate on Meats from Montreal to Mississauga.Item 6830: Establishment of rates on Empty Wooden Pallets from Beauharnois (Maple Grove) to Hamilton and Toronto.Item 7365: Addition of rate from Montreal to Ottawa, on Starch.Item 8618: Establishment of rate on Polyester Yarn from Hawkesbury to Shawinigan.Québec-Ontario Iron and Steel Commodity Tariff 32-G.T.B.Q.2909 amended by addition to Rules 22 and 23 of note \"The arbitrary shown will be assessed on the basis of billed weight\".Québec-Ontario Paper Commodity Tariff 40-G.T.B.Q.2910 amended by addition to Rules 22 and 23 of note \"The arbitrary shown will be assessed on the basis of billed weight\".Québec-Ontario Export and Import Commodity Tariff 45-M, T.B.Q.2808 amended by addition to Rule 22 of note - \"The arbitrary shown will be assessed on the basis of billed weight\".Québec-Ontario Competitive Tariff 71-U.T.B.Q.2926 amended by addition to Rules 35 and 36 of note - \"The arbitrary shown will be assessed on the basis of billed weight\", and addition to Rule 35 of arbitrary rates on 10,000 lbs and 15.000 lbs.Québec-Ontario Container Tariff 74-A.T.B.Q.3372 amended by addition to Page 4 of rates between Montreal and Trenton.Québec-Western Canada Commodity Tariff 1005-D, T.B.Q.3485, amended as follows : 6422 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Poste 450: Augmentation de 6% sur les taux applicables au beurre entre différents endroits.Supplément 1 devra servir à ajuster les taux figurant à l'article 1 ce la liste des tarifs.Tarif 640 applicable aux marchandises en vrac, C.T.2545 modifié pour ajuster et corriger différents taux.Tarif de taux d'urgence Québec-Ontario 2263, C.T.4053, pour les appareils de radio et de télévision.Tarif de taux d'urgence Québec-Ontario 2262, C.T.4052, pour le poisson congelé.Québec-Western Canada Freight, tous genres, et tarif de classe 1030-A, C.T.3041.Tarif de taux d'urgence Québec-Ontario 2257, supplément 1, C.T.4042 pour le fer et l'acier - correction de l'erreur dans le poids minimum.Tarif spécial Québec-Ontario C.T.1171.supplément S, correspondant à une augmentation du taux applicable aux composés résineux et aux résines.Tarif de classe Québec-Ontario 10-E, C.T.1500, modifié comme suit: Regie 287: Augmentation du prix du pesage et du repesage.Correction de la base de tarification K249 W la page 606.Tarif de marchandises Québec-Ontario 15-K, C.T.2805, modifié comme suit: Règle 22: Augmentation des taux arbitraires applicable aux poids de 10,000 lbs et 15.000 lbs.Poste 440: Adjustement des taux applicables aux lingots d'aluminum, de Baie Comeau à Oshawa, Richmond Hill et Toronto.Poste 660: Ajustement des taux applicables à l'alu-minum et aux sulfate d'alumine, de Valleyfield à A \\:, est 212, rue Bloomfield, Outremont, province de Québec.Les procureurs de la compagnie.Paquette, Paquette, 54393-0 Perreault & Rivet.VAN DE HOGEN CARTAGE LTD.Prenez avis que « VAX DE HOGEN CARTAGE LTD.\u2022 a établi une place d'affaires au 500 Place d'Armes, suite 1015.Montréal, endroit où elle transigera ordinairement ses affaires au Québec, où il peut lui être adressé du courrier et où on peut la rejoindre par téléphone au numéro suivant: 288-5682.lœs procureurs de la compagnie, 54421-o Guehtin, GaciN'ON et Lar.ei h.STEEL CITY TRUCK LINES LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"STEEL CITY TRUCK LINES LTD.\", is 212 Bloomfield St.Oiitremont.Province of Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 54393-0 .1 ttorneys for the ( 'ompany.VAN DE HOG EN CARTAGE LTD.Notice is given that \"VAN DE HOGEN CARTAGE LTD.\" has established a place of business at 500 Place d'Armes, Suite 1015, Montreal, where it will generally carry on business, where its mail may be forwarded anil where it may be reached by telephone at the following number: 288-5682.Guertix, Gagxox and Lafleuh.54421 Attorneys for the Company.MOTORWAYS (ONTARIO) LTD.Avis est donné que l'adresse pour la province de Québec de « MOTORWAYS (ONTARIO) LTD.permis numéro I451S-V.est 1900-52' avenue, Lachine.province rice-pré.iidenl, 544l3-o P.I».DaiciLB.CITY NATIONAL LEASING LIMITED Notice is given that \"CITY NATIONAL LEASING LIMITED\" lias established a place of business at 3500 .lean Talon Street West.Montreal.Province of Québec.P.P.Daiuus, 544l3-o I'icc-l'rcsidenl.Ministère des transports Department of Transportation Avis Les chemins ci-après désignés ne seront plus, à l'avenir, entretenus par le ministère des Transports.Comté Chambly.Dans la municipalité de la ville de Boucherville, les chemins suivants: Le Chemin d'Anjou (Pérou) sur une longueur de 3,780 pieds.Le Chemin de Service Nord, du chemin de Touraine jusqu'à l'intersection avec le chemin «l'Anjou sur une longueur de 1,300 pieds.Comté d'Argenteuil.Dans la municipalité de St-André-Est village: L'ancienne route 327 (31), vis-à-vis des lots P-303 et P-301 sur une longueur de 1,200 pieds.Comté de Compton.Dans la municipalité de Eaton canton: Deux parties de l'ancienne route 108 (28) vis-à-vis du lot P-15F du rang VI, sur une longueur de 780 pieds et vis-à-vis des lots 13E, 13F et 131) du rang VII sur une longueur de 1,239 pieds.Comté de Gaspé-Sud.Dans la municipalité de la ville île (Jaspé (Pointe-Jaune) : La route Raymond Côté sur une longueur de 13,334 pieds.Comté de Lévis.Dans la municipalité de Bernières: L'ancienne route No 9 entre les lot» P-446 à P-457 sur une longueur de 4,960 pieds.Comté de Sicolet.Dans la municipalité de Bécancour ville (secteur St-Grégoire) : Le Chemin de la Grande-Rivière, vis-à-vis des lots P-59, P-60, P-62, P-63, P-64 sur une longueur de 2.500 pieds.Comté de Portneuf.Dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmau-res, les chemins suivants: Xolice The road-, hereinafter described will no longer be maintained by the Department of Transport.County of t hambly: In the Municipality of the Town of Boucherville, the following rouds: D'Anjou Road (Pérou) over a distance of 3.7X0 feet.Service Roail North, from De Touraine Rond up to the point where it intersects with d'Anjou Road, over a distance of 1,300 feet.County of Argcnleuil: In the Municipality of St.André-East Village: Former Highway 327 (31), facing lots P-303 and P-301 over a distance of 1,200 feet.County of Compton: In the Municipality of Eaton Township: Two parts of former Highway 108 (2S), facing lot P-15Foi Range VI over a distance of 780 feet and facing lots 13E, 13F and 131) of Range VII over a distance of 1,239 feel.County of Gaspé-South: In the Municipality of the City of (Jaspé (Pointe-Jaune) : Raymond Côte Road over a distance of 13,334 feet.County of UtUi In the Municipality of Bernières: Former Highway No.9 between lots F-446and P-457 over a distance of 4,960 feet.County of Xicolel: In the Municipality of Bécancour Town (St.Grégoire Ward) : De-la-Grandc-Rivière Road, facing lots P-59, P-60, P-62, P-63, P-64 over a distance of 2,500 feet.County of Portneuf: In the Municipality of St.Augustin-de-Desmaures, the following roads: 6432 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U L'ancienne route du Lac St-Joseph, vis-à-vis des lots 58 et 105 sur une longueur de 500 pieds.L'ancien chemin du 5e rang vis-à-vis des lots 59 et 00 sur une longueur de 300 pieds.Comté de Pontine.Dans la municipalité de Campbell's Bay village: L'ancien chemin Campbell's Bay - Otter Lake sur une longueur île 300 pieds.Comte de Témiscamingue.Dans la municipalité de Saint-Kugène de (îuigues: L'ancien chemin Montée (lamachc, vis-à-vis des lots 48 et 49 sur une longueur de 1.000 pieds.Québec, le 6 septembre 1973.54369-0 l.c ministre des transports.Raymond Maii.i.oi x.Former I.ake St.Joseph Road, facing lots 58 and 105 over a distance of 500 feet.Former Road of the 5th Range, facing lots 59 and 60 over a distance of 300 feet.County of I'ontiac: In the Municipality of Campbell's Bay Village: Former Campbell's Bay-Otter Road over a distance of 300 feet.County of Témiscamingue: In the Municipality of St-Eugène-de-Guigues: Former Montée Gaiuachc Road, facing lots 48 and 49.over a distance of 1,600 feet.Québec, September 6.1973.Raymond Maii.lolx, 54369 Minister of Transport.Ventes pour taxes Sales for taxes Ville de Pierrefonds Avis est par les présentes donné que les immeubles ci-dessous décrits, situés dans la Ville de Pierrefonds.seront vendus à l'enchère publique, en la Salle du conseil de l'Hôtel de Ville sise au 11072 boulevard Gouin ouest, le MARDI, le VINGT-SEPTIÈME jour de NOVEMBRE 1973.à DIX heures de lavant-midi pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêt, plus les frais encourus ou qui pourront être encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépens ne soient payés avant la vente.City of Pierrefonds Notice is hereby given that the immovables described hereinuniler.situated in the City of Pierrefonds.will be sold by public auction, in the City Hall of the City of Pierrefonds.situated at 11072 Gouin Boulevard West, on TUESDAY, the TWENTY-SEVENTH day of NOVEMBER 1973.at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy the payment of the municipal and school taxes with interest, plus the costs which have been or may be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale.Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Subdivisions Les Entreprises lïoger Pilon Inc.Avec bâtisses dessus érigées.Davar Construction Inc.Avec bâtisses dessus érigées.Lumont Holding Limited.Avec bâtisses dessus érigées.Gepner Realties lue.Celte partie de lot mesure mille neuf cent deux pieds (1.902') dans sa ligne nord-est.mille huit cent quatre-vingt-un pieds (1.881') dans sa ligne sud-ouest, cent quarante-sept pieds et deux dixièmes de pied (147.2') dans sa ligne nord-ouest et cent soixante-sept pieds (107') dans sa ligue sud-est.Cette partie de lot contient en superficie deux cent quatre-vingt-six mille deux cent dix-neuf pieds carrés et cinq dixièmes de pied carré (280.219.5 pi.ca.) mesure anglaise.Cette partie de lot est bornée au nord-est par une partie des lots 131 et 132, au sud-ouest par une partie du lot 139.au sud-est par le lot 247.(Ville de Dollard-des-Ormeaux) et au nord-ouest par une partie du lot 133.51 .109-5.51.109-0.52.4.With buildings thereon erected.09.2.With buildings thereon erected.107.With buildings thereon erected.294.P.133.This part of lot measures one thousand nine hundred and two feet (1.902') in its northeast line, one thousand eight hundred and eighty-one feet (1,881') in ils southwest line, one hundred and forty-seven feet and two tenths of a foot (147.2') in ils northwest line and one hundred and sixty-seven feet (107') in its southeast line.This part of lot has an area of two hundred and eighty-six thousand two hundred and nineteen square feet and five tenths of a square foot (280,219.5 sq.ft), English measure.This part of lot is bounded to i he northeast by part of lots 131 and 132.to the southwest by part of lot 139, to the southeast by lot 247 (Town of Dollard-des-Ornieaux) and to the northwest by a part of lot 133. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n° U_&*33 Gepner Realties Inc.Cette partie de lot mesure mille huit cent quatre-vingtrun pieds (1,881') dans sa ligne nord-est, mille huit cent soixante-huit pieds et huit dixième de pied (1,868.8') dans sa ligne sud-ouest, cent quarante-cinq pieds (145') dans sa ligne nord-ouest et cent cinquante-deux pieds (152') dans sa ligne sud-est.Cette partie de lot contient en superficie deux cent soixante-cinq mille sept cent soixante-quinze pieds carrés et huit dixièmes de pied carré (265,775.8 pi.ca.).mesure anglaise.Cette partie de lot est bornée au nord-est par une partie du lot 133, au sud-ouest par une partie du lot 140, au nord-est par le lot 247 (Ville de Dollard-des-Ormeaux) et au nord-ouest par une partie du lot 139.Roag Realty Inv.Co.Borné en front au nord-est par la rue Kené-Emard (153-46), au sud-est par une autre partie du lot 153 appartenant a Les Entreprises Roger Pilon Inc.au sud-ouest par une partie du lot 153-44 et au nord-ouest par le lot 153-54.Cette partie de lot mesure sept cent vingt-sept pieds et trois dixièmes de pied (727.3') au nord-est; deux cent pieds et quarante-deux centièmes de pied (200.42') au sud-est; six cent soixante-dix-sept pieds et neuf dixièmes de pied (677.9') au sud-ouest et deux cent trois pieds et trois dixièmes de pied (203.3') au nord-ouest.Contenant en superficie cent quarante-deux mille deux cent quarante pieds carrés (142.240 pi.ca.).mesure anglaise.Shell Construction Co.Shell Construction Co.Shell Construction Co.Shell Construction Co.De figure trapézoïdale, borné au nord-ouest par le cadastre officiel du Village de Sainte-Geneviève, au nord-est par une partie du lot 174, au sud-est par le boulevard Pierrefonds (175-14) et au sud-ouest par une autre partie dudit lot 175.Cette partie de lot mesure trois cent quatre-vingt-un pieds (381') de largeur perpendiculaire par des profondeurs de cinq cent soixante-quatre pieds (564') dans sa ligne sud-ouest et six cent dix pieds (610') dans sa ligne nord-est.Cette partie de lot contient en superficie deux cent vingt-trois mille six cent quarante-sept pieds carrés (223,647.pi.ca.).mesure anglaise.Shell Construction Co.De figure irrcgulière.bornée au nord-ouest par le boulevard Pierrefonds (175-14), au nord-est par une partie non subdivisée du lot 174.au sud-est par la rue Gratton (175-13) et au sud-ouest par une autre partie non subdivisée du lot 175.Cette partie de lot mesure trois cent quatre-vingt-un pieds (381') de largeur perpendiculaire par une profondeur de deux cent quatre-vingt-cinq pieds (285').Cette partie de lot contient en superficie cent huit mille huit cent vingt pieds carrés (108.820') mesure anglaise.The 183 Corporation.Première parcelle: De figure irrégulicre, bornée en front au sud-est par le boulevard Pierrefonds (P1S3), au sud-ouest par une partie du lot 116, les lofs 116-22.116-16 (rue) et 116-15 du cadastre officiel pour le Village de Sainte-Geneviève, au nord-ouest par une partie du lot 119 du cadastre officiel du Village de Sainte-Geneviève et au nord-est par les lots 182-3, 182-4 et 182-60.P.139.This part of lot measures one thousand eight hundred and eighty-one feet (1,881') in its northeast line, one thousand eight hundred and sixty-eight feet and eight tenths of a foot (1,868.8') in its southwest line, one hundred and forty-five feet (145') in its northwest line and one hundred and fifty-two feet (152') in its southeast line.This part of lot has an area of two hundred and sixty-five thousand seven hundred and seventy-five square feet and eight tenths of a square foot (265,775.8 sq.ft.).English measure.This part of lot is bounded to the northeast by part of lot 133, to the southwest by part of lot 140, to the northeast by lot 247 (Town of Do!lard-des-Ormeaux) and to the northwest by a part of lot 139.P.153.Bounded in front towards the northeast by René-Emard Street (153-46), towards the southeast by another part of lot 153.property of Les Entreprises Roger Pilon Inc., towards the southwest by a part of lot 153-44 and towards the northwest by lot 153-54.This part of lot measures seven hundred and twenty-seven feet and three tenths of a foot (727.3') towards the northeast; two hundred feet and forty-two hundredths of a foot (200.42') towards the southeast ; six hundred and seventy-seven feet and nine tenths of a foot (677.9') towards the southwest, and two hundred and three feet and three tenths of a foot (203.3') towards the northwest.Containing a superficial area of one hundred and forty-two thousand two hundred and forty square feet, English measure (142.240 sq.ft.).V.174.174.P.6.174 .58.P.175.Of trapezoidal figure, bounded towards the northwest by the official cadastre for the Village of Ste-Geneviève, towards the northeast by part of lot 174.towards the southeast by Pierrefonds Boulevard (175-14), towards the southwest by another part of lot 175.This part of lot measures three hundred and eighty-one feet (381') in perpendicular width by depths of five hundred and sixty-four feet (564'j in its southwest line and six hundred and ten feet (610') in its northeast line.This part of lot contains a superficial area of two hundred and twenty-three thousand six hundred and forty-seven square feet (223.647'), English measure.P.175.Of irregular figure, bounded towards the northwest by Pierrefonds Boulevard (175-14), towards the southeast by Gratton Street (175-13), towards the southwest by another unsubdivided part of lot 175, and towards the northeast by an unsubdivided part of lot 174.This part of lot measures three hundred and eighty-one feet (381') in perpendicular width by a depth of two hundred and eighty-five feet (285').This part of lot contains a superficial area of one hundred and eight thousand eight hundred and twentv square feet (I0S.820 sq.ft.).English measure.P.183.First parcel: Of irregular figure, bounded in front towards the southeast by Pierrefonds Boulevard (P183) towards the southwest by part of lot 116.lots 116-22.116-16 (street) and 116-15 of the official cadastre for the Village of Ste.Geneviève, towards the northwest by part of lot 119 (Village of Ste.Geneviève) and towards to northeast by lots 182-3, 1s2-4 and 182-60.Noms des propriétaires , .Cadastre Subdivisions Names of proprietors 6434 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 3.1973.Vol.105, No.U Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Subdivisions Cette parcelle de terrain mesure quatre cent quatre-vingt-dix pieds et quatre-vingt-douze centièmes de pied (490.92') au sud-est.quatre cent vingt et un pieds et quatre-vingt-neuf centièmes de pied (421.89') au sud-ouest, quatre cent sept pieds et huit dixièmes de pied (407.8') au nord-ouest et deux cent soixante-deux pieds et trente et un centièmes de pied (262.31') au nord-est.Contenant en superficie 3.37 arpents carrés.Deuxième parcelle: De figure irrégulière, bornée au nord-nues! par le boulevard Pierrefonds (P183Ï.au nord-esl par une partie du loi oiiginaire 182.les lots 182-10 à 182-13 inclusivement, 182-18 a 182-23 inclusivement.182-34.182-50.182-01-1 el une partie du lot 182-61, au sud-ouest par des parties non subdivisées des lois originaires 182, 184 (Paroisse de Sainte-Geneviève, et une partie du lot 116 (Village de Sainte-Geneviève).Cette parcelle de terrain mesure quatre-vingt-dix-huit pieds et soixante-quatre centièmes de pied (98.64') dans ur.e ligne droite et quatre cent quatre-vingt-dix pieds el Irente-sept centièmes de pied (490.37'i le long d'une courbe d'ua rayon de 1.860 pieds sur le boulevard Pierrefonds.deux mil e quatre cent quatre-vingt-huit pieds 12,488') au noid-est, deux cent dix pieds (210') et cent soixante-quatorze pieds (174') dans ses lignes sud-est sur le résidu du iot 183, soixante et onze pieds (71') au sud-ouest sur le résidu du lot 183 et deux mille soixante-sept pieds (2.067') dans sa ligne sud-ouest sur la partie du lot 184 (Paroisse de Sainte-Geneviève) et la partie du lit 116 (Village de Sainte-Geneviève).Contenant en superficie 23.6 arpents carrés.Gepner Realties Inc.Première parcelle: De figure irréguiière.borné au sud-est par une partie du lot 188 (propriété de Arden Construclion Co.Ltd.) par le lot 188-14 (rue) et par le lot 188-13; au sud-nuesl par une partie du lot 192: au nord-ouest par le boulevard Pierrefonds (P.188) et au nord-est par une partie du lot 187-41.par le lot 187-42 (rue Claude), par le lot 187-43.une partie du lot 187 et par une partie du lot 188.propriété de Arden Construction Co.Ltd.Cette dite partie de lot mesure quatre-vingt-dix-neuf pieds et quarante-quatre centièmes de pied (99.44pil et cent soixante-quinze pieds et quatre dixièmes de pied (175.4pi) dans ses limites sud-est: huit cent cinquante pieds plus ou moins (850 pi plus ou moins) au sud-ouest: deux cent quatre-vingt-douze piedî- (292.0pi) au nord-ouest et trois cent trente-cinq pieds (335.0pil et six cent pieds (OOO.Opi) dans ses limites nord-est.Deuxième parcelle: De figure irrégulière, borné au sud-est par le boulevard Pierrefonds (P.188): au sud-ouest par une partie du lot 192; au nord-ouest par le boulevard Gouin.et au nord-est par les lots 187-6.187-7 (nie).187-10.187-11.187-14 (rue).187-17.187-18.187-21 (rue).187-22.187-27.187-28 (rue).187-29.187-34 et une partie du lot 187-35.Cette partie de lot mesure deux cent quatre-vingt-douze pieds (292.Opi) au sud-est: mille cent trente-huit pieds plus ou moin* (1.138 pi plus ou moins) nu sud-ouest; deux cent quatre-vingt-cinq pieds plus ou moins (285.0 pi plus ou moins) au nord-ouest et mille cinquante pieds (1,050.Opi) au nord-est.Ces deux parties du lot 188 contiennent en superficie totale quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-dix-sept pieds carrés, mesure anglaise, (483,777pi.ca.).Avec bâtisses dessus érigées The Two Hundred Nineteen Corp., De figure irrégulière, borné au nord-ouest par les lots 219-50 219-51 (rue).219-52.219-53 et 219-54, au nord-est par le This said pnreel of land measures four hundred and ninety feet and ninetv-two hundredths of a fool (490.92') towards the southeast, four hundred and twenty-one feet and eighty-nine hundredths of a foot (421.89') towards the southwest, four hundred and seven feet and eight tenths of a foot (407.8 ) towards the northwest and two hundred and sixty-two feet and thirty-one hundredths of a foot (262.31 ) towards the northeast.Containing a superficial area of 3.37 square arpents.Second parcel: Of irregular figure, bounded towards the northwest by Pierrefonds Boulevard (P183).towards the northeast by part of lot 182.lots 182-10 to 182-13 inclusively.182-18 to 182-23 inclusively.182-34.182-56.182-61-1 and part of lot 182-61.towards the southwest by part of lot 182, part of lot 184 (Parish of Ste-Geneviève) and part of lot 116 (Village of Ste-Genoviève., This said parcel of land measures ninety-eight feet and sixty-four hundredths of a foot (98.64') in a straight line and four hundred and ninety feet and thirty-seven hundredths of a foot (490.37') along a curve of a radius of 1,860 feet on Pierrefonds Boulevard, two thousand four hundred and eighty-eight feet (2,488') in its northeast line, two hundred and ten feet (210') and one hundred and seventy-four feet (174') in its southeast lines on the residue of lot 183.seventy-one feet (71') in its southwest line on the residue of lot 183 and two thousand and sixtv-seven feet (2.067') in its southwest line on part of lot 184 (Pnrish of Ste-Geneviève» and part of lot 116 (Village of Ste-Geneviève).Containing a superficial area of 23.6 square arpents.P.188.First parcel: Of irregular figure, bounded towards the southeast by part of lot 188 (property of Arden Construction Co.Ltd), by lot 188-14 (street) and by lot 188-13; towards the southwest by-part of lot 192; towards the northwest by Pierrefons Blvd.(P188) and towards the northeast by part of lot 187-41, lot 187-42 (Claude Street), lot 187-43: part of lot 187 and by part of lot 188.property of Arden Construction Co.Ltd.This said part of lot measures ninety-nine feet and forty-four hundredths of a foot (99.44ft) and one hundred and seventy-five feet and four tenths of a foot (175.4ft) in its southeast limits; eight hundred and fifty feet more or less (850ft) in its southwest limit; two hundred and ninety-two feet (292 ft) in its northwest limit and three hundred and thirty-five feet (335ft> and six hundred (eet (600ft) in its northeast limits.Second parcel: Of irregular figure, bounded towards the southeast by Pierrefonds Blvd.(p188) : towards the southwest by part of lot 192: towards the northwest by Gouin Blvd; and towards the northeast bv lots 187-6.187-7 (street).187-10.187-11.187-14.(street).187-17.187-18.187-21 (street).187-22.187-27.187-28 (street), 187-29, 187-34 and part of 187-35.This said part of lot measures two hundred and ninety-two feet (292ft) in its southeast limit, one thousand one hundred and thirty-eight feet more or less (1.138ft) in its southwest limit, two hundred and eighty-five feet more or less (285ft) in its northwest limit and one thousand fifty feet (1.050ft) in its northeast limit.These two part of lot 188 contain a total superficial area of four hundred and eighty-three thousand seven hundred and seventy-seven square feet, English measure (483,777sq.With buildings thereon erected .P.219.Of irregular figure, bounded towards the northwest by lots 219-50, 219-61 (street).219-52.219-53 and 219-54.towards GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1973, 105' année, n° U 643.', Noma des propriétaires Names of proprietors Cadastre Subdivisions résidu du lot 219.au sud-est par le cadastre officiel ce la Paroisse de Sainte-Anne et au sud-ouest par le lot 220 et dans une autre petite ligne sud-ouest par une partie du lot 219-51 (rue).Cette partie de lot mesure deux cent soixante-quinze pieds (275') et cent pieds (100') dans ses lignes nord-ouest et vingt-cinq pieds (25') dans sa ligne sud-ouest sur les lots 219-50 à 219-54 inclusivement, quatre mille cinq cent soixante-sept pieds et trois dixièmes de pied (4,567.3') dans sa ligne nord-est.trois cent soixante -seize pieds (376') dans sa lieue sud-est et quatre mille quatre cent soixante-six pieds (4.466') dans sa ligne sud-ouest.Contenant en superficie 44.15 arpents carres.northeast by the residue of lot 219.towards the southeast by the official cadastre for the Parish of Ste-Anne and towards the southwest bv lot 220 and in another small southwest line by part of lot 219-51 (street).This part of lot measures two hundred and seventy-five feet (275') and one hundred (eet (100') in its northwest line and twenty-five feet (25') in its southwest line on lots 219-50 to 219-54 inclusively, four thousand five hundred and sixty-seven feet and three tenths of a foot in its northeast line, three hundred and seventy-six feet (376') in its southeast line and four thousand four hundred and sixty-six feet (4,466') in its southwest line.Containing a superficial urea of 44.15 square arpents.Les immeubles susdits sont tous du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève et situés dans la Ville de Pierrefonds.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes attachées auxdits immeubles.Donné à Pierrefonds.ce 23e jour d'octobre 1973.Le greffier.54362-44-2-o Gabhiel Lecaii.t.The above immovables are all on the official plan and in the book of reference of the Parish of Ste.Geneviève and situated in the City of Pierrefonds.The said sale will be made with all active and passive servitudes, apparent or occult attached to the said properties.Given at Pierrefonds.this 23rd day of October.1973.Gabriel Lkoailt, 54362-44-2-0 City Clerk: Ville de Pointe-Gatineau Avis public est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la ville de Pointe-Gatineau que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique à l'Hôtel de Ville de la susdite municipalité, 5.boul.du Progrès.MERCREDI le VINGT-HUITIÈME jour de NOVEMBRE 1973, à DIX heures l'avant-midi, pour satisfaife au paiement des taxes municipales et scolaires, avec intérêt, plus les (rais subséquemment encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.La Commission municipale de Québec a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles en date du 26 septembre 1973.Town of Pointe-Gatineau Public notice is hereby given by the undersigned Town Clerk of Pointe-Gatineau that the properties hereinafter described will be sold by public auction at the Town Hall of the above mentioned Municipality, 5 Blvd.du Progrès on WEDNESDAY, the TWENTY-EIGHTH day of NOVEMBER 1973.at TEN o'clock in the morning to satisfy the payment of the municipal and school taxes, with interest, plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale.The Québec Municipal Commission authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the 26th of September 1973.No Nom des propriétaires No de cadastre Taxes munie.Taxes scol.Rôle (int.et frais) (intérêt) Total Roll Owner's Same Cadastral Xo.Munie, taxes School taxes -Vo.{int.and costs) {interest) 7001115 Pointco Inc.588-233.7001212 Pointco Inc.688-240.7001213 Pointco Inc.688-241.7001349 Menard Const.Ltée.588-305.7001350 Menard Const.Ltée.688-306.7003110 Charles Glazer et al.666-34.7005301 Proulx, Gilbert.555-174.7006815 Provost, Jacques.657-50.7008130 Immeubles Tessier Ltée.571-54.7008131 Immeubles Tessier Ltée.571-48.7008132 Immeubles Tessier Ltée.671-47.7013407 Ladouceur, Ludger.518-2.7015629 Beaudin, Jean-Louis.572-56.7016306 Bergeron, Louis.253-7.7017405 Pilon.Real.238-10.7028104 McDermott, Léo.633-1.7021210 Gosselin.Richard.554-40.195.06\t$ 8.45\t9 203.61 581.56\t59.28\t640.84 138.82\t29.14\t167.96 392.02\t102.92\t194 94 433.89\t93.97\t527.86 794.04\t296.75\t1,090.79 1,043.43\t454 21\t1,497.64 998.49\t194.15\t1,192.64 186.64\t23.25\t209.89 146.32\t\t146 32 146.32\t\t146.32 1,093.24\t283.15\t1.376.39 1,594.74\t237.15\t1,831 89 793.68\t122.60\t916.28 545.57\t\t545.57 613.52\t93.55\t707.07 1,151.51\t272.75\t1,424.26 6436 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U No Rôle Roll A'o.Nom des propriétaires Owner's .\\'ame 7025118 Larouche.Michel.7014835 Louis Laflamme in Trust.7016402 Ladouceur, Ludger.7036226 Raschild, Nimire .7036227 Kazanly.Mohamed Aldar.7042118 Ottawa View Dev.Inc.7042204 Leslie Renaud Donald____ 7042413 Maveux, Roger.7042508 Ottawa View Dev.Inc.7042516 Larouche, Jean-Paul.7042605 Larouche, Jean-Paul.7042611 Ottawa View Dev.Inc.7047108 Ottawa View Dev.Inc.7047109 Ottawa View Dev.Inc.7047111 Ottawa View Dev.Inc.7047116 Ottawa View Dev.Inc.7047327 Trustee Anns Gabts.7047328 Trustee Anns Gabst.7047509 McCallum Claire.7047517 Bernardina Spagnoli.7047522 Charette.Oscar.7047525 Schoeder.Rudi.7047526 Guilbeault.Françoise.7047603 Dodaro, Carmen.7048506 Les Galeries d'Or inc.7006804 Lalonde, Henri.7016316 D'Aoust.Daniel.7003118 Petit.Lionel.7003119 Petit, Lionel.7035721 Khouri.Fazi.7035820 Vanasse, Ronald.7006201 Lalanco Ltce.No de cadastre\tTaxes munie.\tTaxes scol.\t \t(int.et frais)\t(intérêt)\tTotal Cadastral No.\tMunie, taxes\tSchool taxes\t \t(int.and costs)\t(interest)\t 488-3.\t531.99\t21.65\t553.64 118.\t1.476.09\t\t1,476.09 254-3.\t913.11\t109.30\t1,022.41 4-89.\t200.30\t61.68\t261.98 4-88.\t176.76\t61.38\t238.14 26-49.\t2,287.27\t32.85\t2.320.12 26-88.\t120.40\t20.15\t140.55 26-56.\t110.41)\t19.55\t130.04 25-29.\t106.63\t23.15\t129.78 26-24.\t113.67\t22 00\t135.67 25-18.\t110.24\t19.55\t129.79 26-09.\t117.72\t\t117.72 33-54.\t104.43\t23.30\t127.73 33-55.\t107.81\t23.70\t131.51 33-57.\t107.81\t23.70\t131.51 33-62.\t2.675.84\t79.25\t2.755.09 34-32.\t117.88\t\t117.88 34-33.\t117.88\t\t117.88 34-53.\t104.76\t40.85\t181.61 34-74.\t119.59\t21.65\t141.24 34-60.\t114.08\t\t114.08 34-69.\t109.74\t\t109.74 34-68.\t153.98\t\t153.98 34-84.\t215.95\t167.23\t383.18 37-46.\t336.15\t116.91\t453.06 557-45.\t956.90\t360.54\t1.317,44 251-18.\t687.19\t183.25\t870 11 566-36.\t1,363.59\t136.42\t1.500.01 566-35.\t857.90\t44.51\t902.41 4-136.\t209.31\t73.78\t283.09 4-193.\t364.94\t49.49\t414.43 557-160 i/to 167.\t14,946.77\t1.868.20\t16,814.97 Des lopins de terre situés ù Pointe-Gatineau connus et désignés comme étant les lots numéros cent soixante-trois, cent soixante-quatre, cent soixante-cinq, cent soixante-six et cent soixante-sept de la subdivision du lot numéro cinq cent cinquante-sept (557-160.161, 162.163.164.165, 166.167) au cadastre du village de Pointe-Gatineau; avec toutes bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.Un lopin de terre connu et désigné comme étant partie du lot cinq cent cinquante-sept non subdivisée (ptie 557 n.s.) au cadastre du village de Pointe-Gatineau; mesurant cent vingt pieds (120') dans ses lignes est et ouest; par deux cent trente-quatre pieds et cinq dixièmes (234.5') dans ses lignes nord et sud, mesures anglaises et plus ou moins; borné comme suit: au nord par le chemin de la Savane ou partie du lot 564; au .sud par les lots 557-164.165.166.167; à l'est par partie du lot 58-1 ; et à l'ouest par les lots 557-160.161 et partie du lot 557-162; avec toutes bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.IV 557 An emplacement situated in the Town of Pointe-Gatineau.Province of Québec, known as being lot number hundred sixty to hundred sixty-six (160 to 166) of the subdivision of the lot number 557 according to the cadastre of Village of Pointe-Gatineau.A piece of laud known as being a part of the lot 557 non sAibdivised according to the cadastre of Village of Pointe-Gatineau; containing hundred twenty feet ( 120') to the east and west and two hundred thirty-four feet and five tenths of a foot (234.5') to the north and south.The whole English measure more or less; hounded to the north by Savane Street to the south by lots 557-164 to 557-167 to the east by part of the lot 58-1 and to the west by the lot 557-160, 557-161 and part of the lot 557-162.7006206 Graveline, Haoul.58- Un emplacement situé à Pointe-Gatineau.province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision non-officielle quatre cent quinze (415 n.o.) de la subdivision officielle un, de la resubdivision du lot originaire cinquante-huit (58-1) au cadastre du village de Pointe-Gatineau.le tout tel que démontré sur un plan préparé par M.G.Hinfret.ar|»eii-teur-géomètre.en date du 25 octobre 1952, ledit lopin de terre mesurant quarante-huit pieds de largeur sur cent pieds de profondeur (48' x 100') mesures anglaises, plus ou moins et borné comme suit: au nord par la route de la Savane, au sud par la subdivision numéro 414, propriété de Nisphas lîicher, à l'est par la subdivision 416, propriété de Nisphas Richer, ou représentants, et à l'ouest par une autre partie dudit lot cinquante-neuf propriété de Immeuble Gatineau Ltée ou représentants.l-(454) P.378.46 12.40 390.85 An emplacement situated in Town of Pointe-Gatineau.Province of Québec, known as being the non official subdivision (415 n.w.) of the official subdivision I, of the resubdivision of the originally lot 58-1 according to the cadastre of Village of Pointe-Gatineau, containing forty-eight feet (48') to the north and south by hundred feet (100') to the east and west.The whole English measure more or less.This piece of land described i.s bounded to the north by Savane Street to the south by the subdivision number 414 to the east bv the subdivision 414 and to the west by lot (557 n.s.). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, h\" 44 6437 No Nom des propriétaires No de cadastre Taxes munie.Taxes scol.Rôle (j\u201et.et frais) (intérêt) Total Roll Owner's Xante Cadastral Xo.M unie, taies School lazes No.(,\u201e4.a\u201ed costs) {interest) 7006715 Menard Const, ltée.58 Un lopin de terre connu et désigné comme étant le lot numéro quatre cent vingt-six de la subdivision non-officielle du lot numéro un de la subdivision officielle du lot numéro cinquante-huit (58-1-426) au cadastre du village de Poiate-Gatineau; aussi connu comme étant la subdivision quatre cent soixante-huit non-officielle (468 n.o.) du même cadastre; mesurant cinquante pieds (50') de largeur par cent cinq pieds (105') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins; borné comme suit: au nord par le lot 58-1-425 propriété de M.Raymond Durant ou représentants: au sud par le lot 58-1-427 propriété de M.Aldcge Corbeil ou représentants; a l'ouest par la rue Michaud; et à l'est par le lot 483 propriété de M.Pierre Charron ou représentants.7008817 Immeubles Tessier inc.571 Un terrain vague, connu et désigné, comme étant une partie du lot cinq cent soixante et onze n.s.aussi connu connue étant le lot cinq cent soixante et onze (571-31 n.o.) démontré sur un plan préparé par Marcel Ste-Marie.arpenteur-géeme-tre.daté du 11 octobre 1973.Borné à l'ouest par le lot cinq cent soixante et onze (571-32 n.o.), au noid par le lot cinq cent soixante et onze (571-30 n.o.) au sud par une rue projetée.7013210 Léonard, Jean-Léopold.557 La moitié indivise d'un lopin de terre connu et désigné comme étant partie du lot numéro cinq cent cinquante-sept non subdivisé (Plie 557 n.s.) au cadastre du village de Pointe-Gatineau, mesurant quarante-sept (47'1 dans sa ligne sud-est; quarante pieds (40') de largeur et cent trente-quatre pieds (134') dans ses lignes est et ouest, mesures anglaises et plus ou moins; borné comme suit : au nord par partie du même lot, propriété de Mme Wilson; au sud-est par la rue St-Lou:s; à i'est par partie du lot 557 n.s.et à l'ouest par le lot 552.-l-(468) P.645.51 21.44 666.95 An emplacement situated in Town of Pointe-Gatineau, Province of Québec, known as being the lot number four hundred twenty-six of the non official subdivision of the lot number one of the official subdivision of the lot fifty-eight (58-1-426) according to the cadastre of Village of Pointe-Gatineau; also known as being the subdivision four hundred sixtv-eight (468) non official of the same cadastre; measuring fifty feet (50) width by hundred five feet (105) depth the all English measure more or less; bounded to the north by the lot fiftv-eight (58-1-425) to the south by the lot fifty-eight (58-1-427) to the west by Michaud street and to the east by I he lot four hundred eighty-three (483) non official.-31 n.off.113.80 21.08 134.88 An emplacement known as lieing a part of the lot five hundred seventy-one.also known lot thirty-one of the n.o.subdivision five hundred seventy-one as shown on the plan prepared by Marcel Ste-Marie, Surveyor, dated from October 11.1973.Bounded to the west by lot.five hundred seventy-one (571-32 n.o.).to the north by lot five hundred seventy-one (571-30 n.o.).to the south by a part of a street.1».377.07 18.50 395.57 An emplacement situated in the Town of Pointe-Gatineau.Province of Québec, known us being a part of the lot five hundred fifty-seven (557) non subdivised.according to the cadastre of Village of Pointe-Gatineau, measuring forty-seven feet (47') in his southwest line, forty feet (40') width and hundred thirty-four feet (134') in his line cast, and west.English measure more or less; bounded to the north by part of the same lot to the southwest by St-Louis street to the east by part of the lot five hundred fifty-seven (557) non subdivised and to the west by the lot five hundred fifty-two (552).7016338 Immeuble Tessier inc.571 P.331.96 46.76 378.72 Un terrain vague connu et désigné cemme étant une partie du lot cinq cent soixante et onze n.s., démontré sur un plan préparé par Marcel Ste-Marie, arpenteur-gétmètre, contenant approximativement vingt-neuf milles cinq cent vingt-quatre pieds carrés, borné au sud par le lot deux cent quarante-deux (242-2).à l'ouest par la rue Marengcre, a l'est par les lots deux cent cinquante et un (251-27 à 251-30) et au nord par le lot cinq cent soixante el onze n.s.An emplacement known as being a part of lot five hundred seventy-one n.s.as shown on a plan prepared by Marcel .Ste-Marie.Surveyor, containing approximately twenty-nine thousand and five hundred twenty-four square feet, bounded to the south by lot two hundred forty-two (242-2) to the west bv Marengcre street, to the east by the lots two hundred fifty-one (251-27 to 251-30) and to the north by the lot five hundred seventy-one n.s.7017317 Fleurant, Lionel Un lopin de terre connu et désigné étant partie des lois (pties 198, 199.200 et 201) au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau.mesurant en tout quarante-cinq pieds (45') dans ces lignes nord et sud par quatre-vingt-trois pieds '83') dans ces lignes est et ouest, mesures anglaises et plus ou moins; borné comme suit: au nord par les dix pieds (10) nord dudit lot 198; au sud par les sept pieds (7') sud du lot 201; à l'est par les quinze pieds (15') est desdits lots 198.199, 200 et 201 et à l'ouest par partie du lot 579-15.198-P.A.76.35 6.20 82.55 201 P.An emplacement known as being a part or the lots (Pts 198, 199.200 and 201) according to the cadastre of the Town of Pointe-Gatineau.measuring forty-five feet (45') in his line north and south and eighty-three feet (83') in his line east and west.English measures more less; bounded to the north by the ten feet (10') north of the same lot 198; to the south by the seven feet (7') south of the lot 201 ; to the east by the fifteen feet (15') east of the lots 198 to 201 and west by part ol the lot 579-15.7016431 Bigras, Simon.569 Un lopin de terre sis et situé à Pointe-Gatineau.connu et désigné comme étant partie du lot numéro cinq cent soixante-neuf (569-ptie) au cadastre du village de Pointe-Gatineau.mesurant quarante-cinq pieds (45') de largeur sur quatre-vingt-huit pieds (88') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, et borné comme suit: Au nord par partie du même lot, propriété de C.Duyal ou représentants; au sud par partie du même lot, propriété de Albert Galipeau ou représentants; à l'ouest par la rue Cousineau et à l'est par le lot numéro 568.p.426.86 S 159.09 S 582.95 An emplacement situated in the town of Pointe-Gatineau.Province of Québec, known as being a part of the lot number 569 pt.according to the cadastre of the Town of Pointe-Gatineau, containing forty-five feet (45') to the east and west and eighty-eight feet (88') to the north and south.The whole English measure more or less.This peace of land is bounded as follows: to the north part of the same lot, to the south by part of the same lot to the west by Cousineau street and to the east by the lot 568. fi438 QVÉliEC OFFICIAL GAZETTE, Nonember 3, 1973, Vol.105, No.U No Nom des propriétaires No de cadastre Taxes munie.Taxes scol.Row (int.et frais) (intérêt) Total Roll Owner's Name Cadastral Ko.Munie, taxes School taxes No.(int.and costs) (interest) Avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendance* et sujet à toutes servitudes actives et passives, apparentes el non apparentes pouvant affecter ledit immeuble portant If numéro civique 113, rue Cousineau, a Pointe-Gatineau, province de Québec.7019525 Lamoureux et frères.4 1.Un lopin de terre, connu et désigne comme étant le lot numéro un de la subdivision du lot numéro quatre cent quatre-vingt (480-1) au cadastre du village de Pointe-Gatineau; monta les emplacement déjà vendus par le présent vendeur à MM.François-Xavier Lortie.Paul-Emile Lamoureux, Bernard Malette.Léo Yelle et al., C'ie d'Habitation Ltée.Jacquet St-Louis.Noël Lamoureux, Joseph Toutloff et Lionel L'Ecuyer.2.Avec toutes bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.Un lopin de terre, connu et désigné comme étant partie du lot numéro un de la subdivision du lot numéro quatre cent quatre-vingt-sept (487-1 ptie) au cadastre du village de Pointe-Gatineau; étant tout le lot moins la partie vendue à Pointco Inc.-1 V.259.88 36.72 296.60 1.An emplacement situated in the Town of Pointe-Gatineau, Province of Québec, known as being the lot number one of the subdivision of the lot number four hundred eighty (480-1) according to the cadastre of the town of Pointe-Gatineau; this property less the emplacements already sold to Misters François-Xavier Lortie, Paul-Emile Lamoureux.Bernard Malette.Leo Velio, C'ie d'Habitations Ltée.Jacques St-Louis.Noël Lamoureux, Joseph Touttlof and Lionel Lécuyer.2.An emplacement known as being a part of the lot number one of the subdivision of the lot number four hundred eighty-seven (487-1 Pt) according to the cadastre of the Town of Pointe-Gatineau containing all the lots less a part all ready sold to Pointco Inc.7023147 Philippe, Séguin, Irène.47 Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro 4 de la subdivision du lot numéro (471 ptie 4) au cadastre du village de Pointe-Gatineau; mesurant cent dix pieds (110') au nord et cent huit pieds (108') au sud de largeur, par mille cinq cent soixante-cinq pieds (1.565') â l'ouest et mille cinq cent quatre-vingt-douze pieds (1,592') à l'est de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins; le tout Irerné comme suit: au nord par partie du lot 470; a l'est par le lot 472-2; au sud par le cent cinquante pieds (150') sud, résidu du lot 471-4, propriété du vendeur et a l'ouest par le lot 464-4, propriété de M.Hégent Séguin; le tout sujet a une servitude de la Commission Hydroélectrique du Québec et enregistré à Hull, sous le numéro 184-233.1\u20144 P.485.97 125.96 611.93 An emplacement known has being a part of the lot number 4 of the subdivision of the lot number (471 pt 4) according to the cadastre of the Town of Pointe-Gatineau; measuring one hundred ten feet (110') to the north and one hundred eight feet (108'> to the south by one thousand five hundred and sixty-five feet (1.565') to the west and one thousand five hundred and ninety-two feet (1,592') to the east, English measures more or less bounded to the north by a part of the lot 470; to the west bv the lot 464-4; to the east by the lot 472-2; to the south by the one hundred fifty feet (150') south, balance of the lot 471-4.7047120 W.T.Shean.33 Un lopin de terre connu et désigné comme étant une partie du lot soixante-six (66) de la sul>division officielle du lot numéro trente-trois (33-66 ptie) de forme irrégulière mesurant dans sa ligne ouest cinquante-six pieds et cinq dixième* (56.5') dans sa ligne nord-ouest soixante-dix pieds et deux dixièmes (70.2') dans sa ligne nord-est cent quatorze pieds et neuf dixièmes (114.9'), dans sa ligne sud-est cinquante-cinq pieds el six dixièmes (55.60, dans sa ligne sud cent pieds (100').Le tout en mesures anglaises plus ou moins; borné comme auit.au nord par la Route numéro 8.au nord-est par le lot trente-trois (33-67 ptie).au sud par le lot trente-trois (33-65) et à l'ouest par la rue St-Antoine.66 P.1,783.01 30.75 1,813.76 An emplacement known afl being a part of the lot sixty-six of the official subdivision of the lot thirty-three (33-66Part) of irregular form measuring in its line west fifty-six feet and five tenths of a foot (56.5') in its line northwest seventy feet, and two tenths of a foot (70.2') in is line northeast hundred fourteen feet and nine tenths of a foot (114.9') in its line southeast fifty-five feet and six tenths of a foot (55.6') in its line south hundred feet (100 ).The whole in English measure, more or less; bounded to the north by the Highway number 8, to the northeast by the lot thirty-three (33-67Part), to the south by the lot thirty-three (33-65) and to the west by St-Antoine street.7048409 Rideau State Inc.Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot 36 au cadastre du village de Pointe-Gatineau, aussi connu comme étant la subdivision non-officielle 47 selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959, de forme triangulaire, borné comme suit au nord par une rue projetée, :\\ l'est par le lot 36-37 n.o., â l'ouest par le lot 35-48 n.s.93.74 2.55 96.29 An emplacement known as being a part of the lot 36 according to the Cadastre of the Town of Pointe-Gatineau, also known as being the subdivision non official 47 as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, the 1st of June 1959.of a triangular form bounded to the north by a projected street to the east by the lot 36-37 n.o.and to the west by the lot 35-48 n.s.3G-47 N.Off, 7049417 Rideau State Inc.3 Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot 36 au cadastre du village de Pointe-Gatineau.aussi connu comme étant la subdivision non-officielle 28A selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959, mesurant approximativement 37.5 de largeur M AN.Off.101.43 16.96 118.38 An emplacement known as being a part of the lot 36, according to the Cadastre of the Town of Pointe-Gatineau, also known as being the subdivision n.o.28-A as shown measuring an approximately to the 37.5 by 136 of depth, bounded to the north by the lot 36-27 n.o.to the east by a GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, S novembre 1973.105' année.n° U 6439 No Nom des propriétaires No de cadastre Taxes munie.Taxes scol.Rôle (int.et frais) (intérêt) Total Roll Owner'i .\\ame Cadastral No.Munie, taxes School taxes A'o.(int.and costs) (interest) par 136' pieds de profondeur borné au nord par le lot 36-27 projected street, to the south by the lot 36-28B n.o.and to n.s., à l'est par un chemin projeté, au sud par le lot 36-28B the west by the lot 36-30 n.o.n.o.et à l'ouest par le lot 36-30 n.o.7048420 Rideau State Inc.36- Un terrain connu et désigné comme étant partie du lot 36 du cadastre de Village de Pointe-Gatineau, aussi connu comme étant la subdivision non-officielle 50A selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959, de forme irrégulière, borné au nord par une rue projetée, à l'est par le lot 36-50B n.o.et au sud par le lot 36-49 n.o.et à l'ouest par le lot 35-56 n.o.\u202250 AN.Off.98.81 15.10 113.91 An emplacement known as being a part of the lot 36 according to the Cadastre of the Town of Pointe-Gatineau, also known as being the subdivision non official 50A.as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor the 1st of June 1959.Irregular form bounded to the north by a projected street to the east by the lot 36-50B n.o.to the south by the lot 36-49 n.o.and to the west by the lot 35-56 n.o.7048426 Rideau State Inc.36- Un terrain connu et désigné comme étant partie du lot 36 au cadastre du village de Pointe-Gatineau, aussi connu étant la subdivision non-officielle 51A selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959.de forme triangulaire, borné à l'est par le lot 36-51B n.s.au sud par un chemin projeté, à l'ouest par partie du lot 35-16 n.o.51 AN.Off.95.74 13.95 109.69 An emplacement known as being a part of the lot 36.according to the Cadastre of the Town of Pointe-Gatineau.also known as being the subdivision non official 51-A as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, the 1st of June 1959, of triangular form bounded to the east by the lot 36-51B, to the south by a projected street and to the west by a part of the lot 35-16 n.o.7048427 Rideau State Inc.3 Un terrain connu et désigné comme étant partie du lot trente-six (36) au cadastre du village de Pointe-Gatineau, aussi connu comme étant la subdivision non-officielle cinquante-deux (52) selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959, de forme irrégulière, borné au nord par une rue projetée, à l'est par le lot trente-six (36-24) non officiel et au sud par le lot trente-six (36-51) non officiel et à l'ouest par le lot trente-cinq (35-15) non officiel.52 n.off.72.92 5.05 77.97 An emplacement known as being a part of the lotthirty-iix (36) according to the cadastre of the Village of Pointe-Gatineau.also known as being the subdivision non official fifty-two (52) as shown on the plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary.Surveyor, the 1st of June 1959, of irregular form bounded to the north by a projected street, to the east by the lot thirty-six (30-24) non official, to the south by the lot thirty-six (36-51) non official, and to the west by the lot thirty-five (35-15) non official.7048428 Rideau State Inc.36 Un terrain connu et désigné comme étant partie du lot trente-six (36) au cadastre du village de Pointe-Gatineau, aussi connu comme étant la subdivision non officielle vingt-quatre (24A) selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959.mesurant cinquante pieds (50') de largeur par cent pieds (100') de profondeur, borné comme suit au nord par une rue projetée, à l'est par le lot trente-six (36-24B) non officiel, au sud par le lot trente-six (36-25A) non officiel, et à l'ouest par le lot trenle-six (36-52) non officiel.-24 A n.off.124.61 334.56 459.17 An emplacement known as being a part of lot thirty-six (36) according to the Cadastre of the Village of Pointe-Gatineau, also known as being the subdivision non official twenty-four (24A) as shown on the plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary.Surveyor, the 1st of June 1959.measuring fifty-feet (50') width by hundred feet (100') depth bounded to the north by a projected street to the east by the lot thirty-six (36-24B) non official, to the south by the lot thirty-six (36-25A) non official, and to the west by the lot thirty-six (36-52) non official.7048603 Georges Alexopoulos.3 Un terrain connu et désigné comme étant partie du lot 36 au cadastre de la ville de Pointe-Gatineau aussi connu comme étant la subdivision non officielle I7A selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959: mesurant cinquante pieds (50') de largeur par cent pieds (100') de profondeur, borné au nord par le lot 36-16A et B, au sud par une rue projetée, à l'est par le lot 36-17B.Le tout, mesure anglaise, plus ou moins.17A n.o.137.88 137.88 An emplacement known as being a part of the lot 36, according to the cadastre of the Town of Pointe-Gatineau.also known as being the subdivision non official 17A as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, the 1st of June 1959; measuring fifty feet (50') of breadth and one hundred feet (IOC) of depth; bounded to the north by the lot 36-10A et B to the south by a projected street, to the cast by the lot 36-17B the whole English measure more or less.7048608 Duval, René.3 Un certain terrain de forme rectangulaire faisant partie du lot trente-six aussi connu comme étant une partie d'i lot trente-six (36-18B Ptie n.o.) démontré dans un plan préparé par M.Jean-Paul Alary.1er juin 1959.borné au nord par la Route numéro 8.à l'est par le lot trente-six (36-16A n.o.), au sud par le lot trente-six (36-19A n.o.) et l'ouest par une rue projetée.18Bn.off.343.61 7.90 351.51 An emplacement known as being a part of the lot thirty-six.also known as being lot thirty-six (36-18B part n.o.) as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary.June 1st, 1959, bounded to the north by the Highway number 8, to the east by lot thirty-six (36-16A n.o.).to the south by lot thirty-six (36-19A n.o.) and to the west by a projected street. f>440 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 3, 1973, Vol.105, No.U No Nom des propriétaires No de cadastre Taxes munie.Taxes «col.Rôle F (int.et frais) (intérêt) Total j?©// Owner'» Xame Cadastral Xo.Munit, taies School taxes Xo.(int.ana costs) (interest) 7048612 Ride State Inc.35-2B n.off.1.456.00 430.20 1 .ks6 20 Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot 35 au cadastre du village de Pointe-Gatineau.aussi connu comme étant le lot 35-2B n.o., selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre le 1er juin 1950.mesurant cinquante pieds (50') de largeur par cent vingt pieds (120') de profondeur, borné au nord par la route 8, à l'est par le lot 35-3 n.o.au sud par le lot 35-9 n.o.à l'ouest par le lot 35-2A.n.o.An emplacement known as being a part of the lot 35 according to the Cadastre of the Town of Pointe-Gatineau also known as being the lot 35-2B n.o., as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, the 1st of June 1959, measuring fiftv feet (50') of breadth and one hundred twenty feet (120') of depth, bounded to the north by highway number 8.to the east by the lot 35-3 n.o.to the south by the lot 35-9 n.o.and to the west by the lot 35-2A n.o.7048614 Ayiscontoyaunis 35-1A ABn.off.485.69 485.69 Un terrain vague connu et désigné comme étant partie du lot 35 du cadastre de la ville de Pointe-Gatineau aussi connu comme étant le lot 35-1A et B ptie et ptie 35-2A.35-10A et B.35-OA (n.o.) selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959; borné au nord par la route No 8.à l'est par le lot 35-9B n.o.et 35-2B n.o.au sud par la rue projetée et à l'ouest par la limite du lot 34.An emplacement known as being a part of the lot 35, also known as being the subdivision non official 35-1A et B part.35-2A pt.35-1 OA and B, 35-9A as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, on the 1st of June 1959; bounded to the north by the highway No.8, to the east by the lot 35-2B n.o.and 35-9B n.o, to the south by a projected street and to the west by the limit of the lot 34.7048704 Gaston Valiquette.36-5B n.off.Un certain terrain de forme rectangulaire ou carré faisant partie du lot (p.36) selon les plans et livre de renvoi du cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, division d'enregistrement de Huit, décrit comme.suit: Commençant à un point sur la ligne est du lot 36 situé à une distance de mille quatre-vingt-treize pieds et un dixième (1.093.1') au sud de l'intersection de la ligne sud-est.du Chemin public (Route numéro 8) avec ladite ligne est du lot 36, ce point étant appelé le point de départ: de là.allant vers le sud, longeant la ligne est dudit lot 36, une distance de cent pieds (100') de là.vers le nord, à angle droit, une distance de cent pieds (100'); de là, vers l'est, à angle droit, une distance de cent pieds (100') jusqu'au point de départ.Ce terrain est borné comme suit: au nord et au sud par d'autres parties du lot 36; à l'ouest par une partie du lot 36 réservé par une rue.à l'est par le lot 37.Contenant une superficie de dix mille pieds carrés (10,000' carrés) le tout en mesure anglaise, et aussi connu étant le lot numéro 5 « A » et n B « de la subdivision n.o.du lot numéro (36-5AB n.o.).124.79 124.79 An emplacement known as being a part of the lot 36, also known as being the lot 35-5A et B n.o., as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, the 1st of June 1959; measuring approximately the subdivision of one hundred feet (100') of breadth and one hundred feet (100') of depth; bounded to the north bv the lot 36-6A & B n.o., to the south by the lot 36-4A & B.to the east by the lot 37-12 to 14 and to the west by a projected street.7048707 Lamouillcre, Francis 36-8 A A: B n.o.180.89 IMi 89 In certain terrain de forme carrée faisant partie du lot (P.36) selon les plan et, livre de renvoi du cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau division d'enregistrement de Hull, décrit comme suit: Commençant à un point sur la ligne est du lot 36 situé à une distance de sept cent quatre-vingt-treize pieds et un dixième (793.1) au sud de l'intersection de la ligne sud-est du Chemin public (Route numéro 8) avec ladite ligne est du lot 36, ce point étant appelé le point de départ: de là, allant vers le sud.longeant la ligne est dudit lot 36, une distance de rent pieds (100') de là, vers l'ouest à angle droit, une distance de cent pieds (100/) de là, vers le nord, à un angle droit, une distance de cent pieds (100') de là.vers l'est à un angle droit, une distance de cent pieds (100') jusqu'au point de départ.Ce terrain est borné comme suit: au nord et au sud par d'autres parties du lot 36; à l'ouest par une partie du lot 36 réservé pour une rue; à l'est par le lot 37.Contenant une superficie de dix mille pieds carrés (10,000' carrés).Le tout en mesure anglaise.An emplacement known as being a part of the lot 36, also known as being the lot 36-8A & B n.o.as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, the 1st of June 1959; measuring one hundred feet (100') of breadth and one hundred feet (100') of depth, bounded to the south by the lot 36-7A & B n.o., to the west by a projected street, to the north by the lot 36-9A & B n.o., to the east bv the lot 37-5 to 7.Donné à Pointe-Ciatineaii, P.Q., ce 25c jour du mois Given at Pointe-Gatineau, P.Q., this 25th dav of d'octobre 1073.October 1973.l.e greffier, Louis Lamarche, o.m.a., 54381-44-2-0 Lous Lamarche, o.m.a.54381-44-2-o Town Clerk. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1973, 105' année.11° M 6441 Ville d'Anjou Avis est par la présente donne, que le Conseil municipal, par une résolution en date du 24e jour d'octobre 1973, a ordonné au soussigné, conformément à la Loi des cités et villes de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes ducs à la Aille d'Anjou, avec intérêts et frais, et qu'en conséquence lesdits immeubles seront vendus par encan public dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Aille d'Anjou 7701, Louis-Hippolyte l.afontainc, le VINGT-HUrriÊME jour de NOVEMBRE 1973.à DIX heures de l'avant-midi, heure normale de l'est.Toutefois, seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels les taxes municipales et scolaires, tant générales que spéciales de l'année 1972 et des années antérieures auront été payées avant le moment de la vente.Permission a été accordée par la Commission muni cipalc de Québec pour autoriser une enumeration abrégée des numéros cadastraux.Les immeubles ci-après décrits seront vendus sujets au droit de retrait d'un an.du cadastre officiel «le la Paroisse de Longue-Pointe, dans les limites de la Ville d'Anjou.Ils seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances s'il y a lieu, sujets à tous les droits acquis de la Ville d'Anjou et à toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes pouvant les affecter.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement, en monnaie légale.City of Anjou Public notice is hereby given, that the City Council by a resolution dated October 24th 1973, has ordered the undersigned, persuant to the Cities and Towns act: to sell the immovables hercinunder described for nonpayment of taxation arrears owing to the corporation of the City of Anjou, with interest and cost, and that consequently the said immovables shall be sold by public auction in the Council room at the City Hall of Anjou.7701.I.ouis-Hippolvte Lafontaine, City of Anjou, on the TWENTY -EIGHTH day of NOVEMBER 1973 at TEN o'clock in the forenoon, eastern standard time.However, there shall be excluded from the sale, the immovables on which municipal and school taxes, so general as special for the year 1972 and previous years shall have been paid prior to the sale.The Québec Municipal Commission has authorised the City of Anjou, an abriged form of cadastral numbers.Immovables hereafter described will be sold, subject to the one-year right of redemption, of official cadastic of Parish Longue-Pointe, within the limits of the City of Anjou.They shall be sold with buildings erected thereon, circumstances and dependencies if any.subject to all the acquired rights of the C'itJ of Anjou, and any servitudes both active and passive, apparent or un-apparent which may affect them.The purchase price of said immovables shall be payable immediately, in legal currency.Vente d'immeubles pour non-paiement des taxes \u2014 Sale of immovables for non-payment of taxes Immeubles sujets au droit de retrait d'un an \u2014 I m movables subject to a righl of redemption of one //ear (Les lots ci-après décrits sont du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe dans les limites de la Ville d'Anjou \u2014The lots hereafter described are of the official cadastre of the parish of Longue-Pointe in the limits of the City of Anjou).Folios Nom et adresse A'orac and address Description de l'immeuble Description of immovable 414-0068 Pierre Bérubé, 1549, Jolliet.414-0090 Albert Forget, Jean Miron, meaux.Montréal.414-0091 Albert Forget, Jean Miron meaux, Montréal.414-0116 Sharand Construction Ltd.414-0119 Albert Forget, Jean Miron, meaux.Montréal.414-0120 Albert Forget, Jean Miron, meaux.Montréal.414-0121 Albert Forget, Jean Miron.meaux, Montréal.414-0122 Albert Forget, Jean Miron, meaux, Montréal.414-0142 Sharand Construction Ltd., 414-0146 Albert Forget, Jean Miron meaux.Montréal.414-0167 Albeit Forget, Jean Miron meaux, Montréal.Chomedey, Laval.Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier.2724.Désor- Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier, 2724.Désor- a's Mrs.Foy.P.O.Box 425 Snowdon St., Montréal Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724.Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier.2724.Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier, 2724, a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425, Snowdon St., Montreal Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor-Désor-Désor-Désor- Désor- Charlemagrie St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 414-187 414-211 414-212 414-261 414-278 414-279 414-280 414-281 414-405 414-433 414-472 6442 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Folios Nom et adresse A'amc and address Description de l'immeuble Description of immovable 414-0168 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor-meaux, Montréal.r, 414-0171 Marcel Picard et/and Mme/Mrs.It.Marchand, née/born Claire Picard, 11325, Ste-Ga-therine est, Montréal.414-0180 Albert.Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier, 2.24.Dcsor-meaux, Montréal.415-0238 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700 boul.Yves Prévost, Anjou.415-0239 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700 boul.Yves Prévost, Anjou.415-0240 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700.boul.Yves Prévost, Anjou.415-0254 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bide, apt 509, Montreal.415 0255 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509, Montieal.415-0257 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700.boul.Yves Prévost, Anjou.415-0258 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost.Anjou.415-0259 Les Immeubles Anjou Liée.7700.boul.Yves Prévost.Anjou.415-0261 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Yves Prévost, Anjou.415-0262 Les Immeubles Anjou Ltée.7700, boul Yves Prévost, Anjou.415-0263 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.415-0265 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-0266 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-0267 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal 415-0268 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509, Montreal.- 415-0303 Sharand Construction Ltd.a.'s Mrs.Foy, P.O.Box 425.Snowdon St., Montreal.415*-0310 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-11311 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509, Montreal.415-0322 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Yves Prévost.Anjou.415-0323 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Yves Prévost.Anjou.415-0325 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-0326 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-0327 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-0328 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-0331 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-0332 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-0338 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.bold.Yves Prévost, Anjou.415-0341 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.415-0342 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Yves Prévost, Anjou.415-0344 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Yves Prévost, Anjou.415-0345 Sharand Construction Ltd., a s Mrs.Foy.P.O.Box 425.Snowdon St.Montreal.415 034S Albert Forget.Jean Miron, Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier, 2724.Désor-meanx.Montréal.415-0373 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Blcg, api 509, Montreal.415-0374 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-0375 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509, Montréal.415-0376 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.api 509, Montreal.415-0392 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700.boul.Yves Prévost, Anjou.415-0393 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Vves Prévost, Anjou.415-0394 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.416-0395 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700.boul.Yves Prévost, Anjou.415-0401 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415 0402 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 590, Montreal.415 0403 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415 0404 Créuiozie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-0405 Crémazie Investment Corp.Doluinion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415 04211 Les Immeubles Anjou Ltée.7700, boul.Yves Prévost.Anjou.415-0421 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boni.Yves Prévost, Anjou.415-0422 Lés Immeubles Anjou Ltée, 7700.boul.Yves Prévost, Anjou.415-0423 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700.boul.Yves Prévost.Anjou.415-0424 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.415-0426 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.415-0427 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.415-0428 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, l>oul.Yves Prévost, Anjou.415-0429 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost.Anjou.\u2022115-0477 Crémazie Investment Corp., Dominion Sep Bldg.apt 509, Montreal.415-0478 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-0479 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal .415-0480 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-0485 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-0486 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-0488 Crémazie Investment, Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-0489 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-0490 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-0491 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509, Montreal.415-0492 Crémazie Investment Corp , Dominion Sq.Bldg.apt 509, Montreal.415-0503 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.414-473 414-487 414-505 415-46 415-47 415-48 415-62 415-63 415-65 415-66 415-67 415-69 415-70 415-71 415-73 415-74 415-75 415-76 415-111 415-118 415-119 415-130 415-131 415-133 415-134 415-135 415-136 415-139 415-140 415-140 415-149 415-150 415 152 415 153 415-156 415-181 415-182 415 183 415-184 115-200 415 201 115 202 115-203 415-209 415-210 415-211 415-212 415-213 415-228 415-229 415-230 415-231 415-232 415 233 415-235 415-236 415 237 415 285 415 280 415-287 415-288 415-293 415-294 415-296 415-297 415-298 415-299 415-300 415-311 GAZETTE OFFICIELLE DU QDÊBEC, 3 novembre 1973.tOô- année.>/\" U 6443 folios Nom et (dresse Xamr and address Description de l'immeuble Description of immovable 415-0524 Crémazie Investment Corp.415 0505 Crémazie Investment Corp.415 0506 Crémazie Investment Corp.415-0507 Crémazie Investment Corp.416-0606 Crémazie Investment Corp.415 0500 Crémazie Investment Corp.415 0510 Crémazie Investment Corp.415-0512 Crémazie Investment Corp, 415-0513 Crémazie Investment Corp.415 0514 Crémazie Investment Corp.415-0515 Crémazie Investment Corp.415-0516 Crémazie Investment Corp.415-0517 Crémazie Investment Corp, 416-0638 Albert Forget, .lean Miron, meaux, Montreal.415 0542 Crémazie Investment Corp.415-0543 Crémazie Investment Corp.415-0544 Crémazie Investment Corp.415-0540 Crémazie Investment Corp.415-0550 Crémazie Investment Corp 415-0551 Crémazie Inve.-tment Corp.415-0552 Crémazie Investment Corp.415-0553 Crémazie Investment Corp.415-0554 Crémazie Investment Corp.415-0567 Crémazie Investment Corp.415 0568 Crétnazie Investment Corp.415 0560 Crémazie Investment Corp.415-0572 Crémazie Investment Corp.415-0573 Crémazie Investment Corp.415-0574 Crémazie Investment Corp.415-0575 Crémazie Investment Corp.415-0605 Albert Forget.Jean Miron meaux.Montréal.415-0635 Crémazie Investment Corp 415 0636 Crémazie Investment Corp 415-0637 Crémazie Investment Corp Le lot 415-420.à distraire toutefois la | Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-312 Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415 313 Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-314 Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415 315 Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415 316 Dominion Sq.Bldg, apt 509 Montreal.415 317 Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415 318 Dominion Sq.BldK.apt 509.Montreal 415 320 Dominion Sq.Bldg.apt 509, Montreal 415 321 Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-322 Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal .415-323 Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal .- 415-324 Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-325 Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724.Désor- 415 336 Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-350 Dominion So.Bldg, apt 509.Montreal .415 351 Dominion Sq.Bldg.api 509.Montreal 415-352 Dominion Sq.Blcliî.509.Montreal 415 357 Dominion Sq.Bldg.api 509.Montreal 415-368 Dominion Sq.Bldg.api 509.Montreal.415-359 Dominion Sq.Bldg.api 509.Montreal 415-360 Dominion Sq Bldg.apt 509.Montreal 415 361 Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montréal .415-362 Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal 415-375 Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal 415-376 Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415 377 Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal 415-380 Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal 415-381 Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415 382 Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415 383 Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier.2724, Désor- 415-404 ., Dominion Sq.Bldg.apt .Dominion Sq.Bldg.apt ., Dominion Sq.Bldg.apt lartie servant de nie.509, Montreal.415-427 509.Montreal.415-428 509.Montreal.Lot 415-429.to withdraw however the part used as a M reel.415-0639 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.Le lot 415-430.a distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-430.to withdraw however the part used as a street- 415-0646 Crc'mazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.i!s~m 415-0649 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Yves Prévost, Anjou 415-437 415-0650 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Yves Prévost.Anjou.*'f-438 415-0651 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700.boul.Yves Prévost.Anjou.415 439 415-0652 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Yves Prévost.Anjou.4i5-440 415-0653 Les Immeubles Anjou Ltée.7700, boul.Yves Prévost.Anjou .415-441 415-0654 Les Immeubles Anjou Liée.7700.boul.Yves Prévost.Anjou.4!f\"11?415-0657 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal .415-445 415 0658 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, api 509, Montreal.415-44b 415-0667 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal Le lot 415-453.à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-453, to withdraw however the part used as a street.415 0668 Les Immeubles Anjou Liée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-454, h distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-454, to withdraw however the part used as a street.415-0670 Les Immeubles Anjou Ltée.7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-455, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-455, to withdraw however the part used as a street.415-0672 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost.Anjou.Le lot 415-456.à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-456, to withdraw however the part used as a street.415-0674 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost.Anjou.Le lot 415-457, a distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-457, to withdraw however the part used us a street.415 0670 Les Immeubles Anjou Liée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-458, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-458.to withdraw however the part used as u street.415-0678 Les Immeubles Anjou Ltée.7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-459, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-459, to withdraw however the part used as a street. 6444 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, November 3.1973, Vol.10b.No.U Folie Nom et adresse Xamr and address Description de l'immeuble Description of immovable to withdraw however the part used as a street, to withdraw however the part used as a street, to withdraw however the part used as a street, to withdraw however the part used as a street, to withdraw however the part used as a street, to withdraw however the part used as a street-to withdraw however the part used as a street, to withdraw however the part used as a street.A site composed of part of lot 416-490, measuring 79.04 feet in width I» 747.54 feet in depth ha inc an area of 59,085.56 square feet, Knglish measure ana inure or less and bounded as follows, to wit: on the north by lot 416-489 (homologated line of the Metropolitan Blvd.).on the south and west by the residue of said lot 416-490 and on the east by a part of lot 416-488.415-0680 Les Immeubles Anjou Ltée.7700, boul.Yves Prévost.Anjou.Le lot 415-460, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-460, 415-0682 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-401, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-461, 415-0684 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-462, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-462, 415-0680 Les Immeubles Anjou Liée, 7700.boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-463, à distraire loulefois la partie servant de rue.Lot 415-463.415-0688 Les Immeubles Anjou Ltée.7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-464, h distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-4114, 415-0690 Les Immeubles Anjou Liée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-465.à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-465, 415-0692 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-460, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-566, 415 0694 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-467.à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-467, 320-1484 Dante lleiine, 6794, c'hoisy.St-Léonard.l'n emplacement composé d'une partie du lot 416-491), mesurant 79.04 pieds de largeur par 747.54 pieds de profondeur et contenant une superficie de 59,085.56 pieds carrés mesure anglaise et plus ou moins, et borné comme suit: savoir: au nord par le lot 416-489 (ligne homologuée du boul.Métropolitain), au sud et a l'ouest par le résidu dudit lot 416-490 et à l'est par une partie du lot 416-488.417-0060 F.pinette Construction, 4275 Kent Ave., Montréal.417-52 417-0061 Kpinette Construction.4275 Kent Ave., Montréal.41.53 417-0210 ICpinette Const.Corp.4275.Kent Ave.Montreal.417-197 417-0218 Sharand Const, Ltd.a/s Mrs.Fov.P.O.Box 425, Snowdon St., Montreal.417-205 417-0219 Sharand Const, Ltd., n/s Mrs.Foy, P.O.Box 425, Snowdon St.Montreal.417-206 417-0235 Albert Forgel, Jean Miron, Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier, 2724.Désor- 417-222 meaux.Montréal.417-0237 Albert Forget, Jean Miron.Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier, 2724.Désor- 417-224 meaux.Montréal.417-0238 Albert Forget, Jean Miron.Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier.2724.Désor- 417 225 meaux, Montréal.417-0239 Albert Forget, Jean Miron.Charlemagne Sl-Onge.Anthime Trépanier.2724, Désor- 417-220 meaux.Montréal.417-0252 Sharand Const.Ltd.a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425.Snowdon St., Montreal.417-239 417-0253 Sharand Const, Ltd., a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425.Snowdon St.Montreal.417-240 417-0285 Sharand Const, Ltd.a/s Mrs.Fov.P.O.Box 425.Snowdon St.Montreal.417-272 417-0280 Sharand Const.Ltd.a/s Mrs.Fov.P.O.Box 425.Snowdon Si.Montreal.417-273 417-0297 Gary Ball.0655.Côte des Neiges.\" lioom/Chainhre 240, Montreal.417-284 417-0298 Gary Ball, 6655, Côte des Neiges, ltooin/Cliaiiibre 240.Montreal.417-285 417-0299 Albert Forget.Jean Miron.Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier.2724, Désor- 417-286 meaux, Montréal.417-0300 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier.2724.Désor- 417-2S7 meaux, Montréal.417-0301 Albert Forget, Jean Miron.Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier.2724, Désor- 417-28S meaux, Montréal.417-0361 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier.2724, Désor- 417-348 meaux, Montréal.417-0362 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier.2724, Désor- 417-349 meaux, Montréal.417-0370 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs.Fov, P.O.Box 425.Snowdon St., Montreal.417-357 417-0372 Sharand Construction Ltd.a/s Mrs.Fov.P.O.Box 425, Snowdon St.Montreal 417-0396 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-3S3 meaux, Montréal.417-0404 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs.Fov.P.O.Box 425, Snowdon St.Montreal.417-391 417-0405 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs.Fov.P.O.Box 425, Snowdon St.Montreal.417-392 417-0426 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425, Snowdon St.Montreal.417-413 417-0429 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-416 meaux, Montréal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973.105' année, m\" U 6445 Folios Nom et adresse Same and address Description de l'immeuble Description of immovable 417-0430 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier.2724.Désor- 417-417 meaux, Montréal.417-0558 Epinette Const.Corp., 4275, Kent Ave., Montreal.417-545 417-0559 Albert Forget, Jean Miron.Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-540 meaux, Montréal.417-0560 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier.2724.Désor- 417-547 meaux.Montréal.417-0501 Albert Forget.Jean Miron, Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-548 meaux, Montréal.417-0562 Gary Bail.6655.Côte des Neiges.Chambrc/Room 240.Montréal.417-549 417-0568 Albert Forget.Jean Miron, Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier.2724.Désor- 417-555 meaux.Montréal.417-0569 Albert Forget.Jean Miron.Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-556 meaux.Montréal.417-0570 Albert Forget.Jean Miron.Charlemagne 3t-Onge.Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-557 meaux.Montréal.417-0574 Gary- Bail.6655.Côte des Neiges, Chambre/Room 240, Montréal.417-561 515-0164 Romano Bartoloméo.2870.Paradis, Montréal.418-78 418-81 5-0036 Giovanni Const.Ltée.10220.Ksplanade.Montréal.418-120 418-121 418-122 515-0240 Giovanni Const.Ltée, 10220.Esplunade.Montréal.418-123 515-0720 Epinette Const.Corp., 4275 Kent Ave.Montréal.Le lot 418-335.à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 418-335, to withdraw however the part used as a street.395-0164 Hector Fournier, 7367, lthéaume, Anjou.419-213 419-214 395-0232 M.Mme/M r.Mrs.Guy Cloutier, née/born Emelda Smith.7469, Rhéaume, Anjou.419-231 419-232 395-0260 Claude Dufour, 7499, lthéaume.Anjou.Le lot 419-238 et une partie du lot 419-237 mesurant cette Lot 419-238 and a part of lot 419-237, measuring this said dite partie 15.2 pieds de largeur par 70 pieds de profondeur et part 15.2 feet in width by 70 feet in depth and containing contenant une superficie de 1.064 pieds carrés, mesure anglaise an area of 1.064 square feet.English measure and more or et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par le less, and bounded as follows, to wit: on the north by lot lot 419-238, au sud par le lot 419-408.& l'ouest par la rue 419-238.on the south by 419-308, on the west by Rhéaume Rhéaume (419-244) et à l'est par une partie du lot 419-349.street.(419-244) and on the east by a part of lot 419-349.295-0436 Harrv Flander.8075.Lafontaine.Montréal.419-353 295-0802 Les Bonnes Entreprises Inc., 5465.Queen Mary Road.Montréal.419-411 295-0810 Centurv Holdings Ltd.5465 Queen Mary Koad.Montreal.419-413 5-0121 Clément Proulx.8795.Alexandre.Anjou.420-240 420-241-1 270-0546 Guy Lébeillé, 0986, Guy, Anjou.420-377-2 270-0554 Claude Sanschagrin.2130, rue Fleury.Montréal.420-379 345-0014 Roger Colas.50.Maplewood, Outremont, Montréal.420-497 345-0360 Roger Colas, 50, Maplewood, Outremont, Montréal.420-561 345-0364 Roger Colas.56, Maplewood, Outremont, Montréal.420-562 345-0368 Roger Colas.56, Maplewood.Outremont.Montréal.420-563 270-0582 Roger Colas.56.Maplewood, Outremont, Montréal .420-564 270-0580 Roger Colas, 56.Maplewood.Outremont.Montréal.420-565 270-0590 Roger Colas.56.Maplewood.Outremont.Montréal.420-506 270-0594 Roger Colas.56.Maplewood.Outremont.420-567 345-0372 ltoger Colas.56.Maplewood.Outremont.420-568 345-0436 Morov Inc.2033.Belgrade.Montréal.420-600 025-0198 Les Immeubles Reno Inc.& Dev.Versailles Inc.7711.Curé Clermont.Anjou.I* lot 423-121.a distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 423-121.to withdraw however the part used as a street.025-0206 Les Immeubles lleno Inc.& Dev.Versailles Inc.7711.Curé Clermont.Anjou.Le lot 423-122, a distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 423-122, to withdraw however the pari used as a street.030-0712 Pierre Marchand, 7451.Baldwin.Anjou .a) Cnc partie du lot 423-195 mesurant cettedite partie 15 (a) A part of lot 423-195 measuring this said part 15 feet Pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une in width by 67 feet in depth and containing an area of 1,005 .\u2014J- ¦ nnc -c.-\u2014* .« A\u201e square feet.English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by another part of said lot 423-195.on the south by a part of lot 423-196.as described below in (It), on the west by another part of said 423-195, and on the east by a part of lot 423-219 as described below in (d).dessous d).b) Le lot 423-196, à distraire toutefois la partie expropriée.(b) Lot 423-196, to withdraw however the expropriated part. » \u2022 1 ! > '.QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3.1973, Vol.106, No.U Folio* Nom et adresse Same and add'css Description de l'immeuble Description of immovable t) One partie du lot 433-197, mesurant cettedite partie 15 Pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une superficie de 1.005 pieds carres, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-196 décrite ci-haut a), au sud par une partie du lot 423-197-1.i l'ouest par le résidu dudit lot 423-197.et i l'est par une partie du lot 423-219 décrite ci-dessous rf).d) t'ne partie du lot 423-219 mesurant cettedite pnrtie 60 pieds de long arriére des parties de lots ci-haut mis en vente par 5 pieds de profondeur et contenant une superficie de \")0 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord, au sud et à l'est par d'autres Parties dudit lot 423-219 et i\\ l'ouest par une partie du lot 423-195 décrite ci-haut n).par une partie du lot 423-196 décrite ci-haut h) et par une partie du lot 423-197 décrite ci-haut c).030-2232 Frank Dingle, 7022, Bald win, Anjou .n) fne partie du lot 423-305 mesurant cettedite partie 30 pndl de largeur par 72 pieds de profondeur et, contenant une superficie de 2.160 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-304.au sud par une partie du lot 423-306 décrite ci-dessous b).à l'ouest par des parties des lots 424-491-19 et 424-491-18 et à l'est par le résidu dit lot 423-305.b) lue partie du lut 423-306, mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur et contenant une superficie de 2.160 pieds carrés et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-305.i i-dessus décrite a), au sud par une partie du lot 423-307.à l'ouest par des parties des lots 424-491-18 et 424-491-17 et à l'est par le résidu dudit lot 423-300.030-1000 Frank Dingle.7022, Baldwin, Anjou .a) Fne partie du lot 423-307, mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur et contenant une superficie de 2,160 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-306.au sud par une partie du lot 423-308.ci-dessous décrite M.à l'oue-t par des parties des lots 424-491-17 et 424-491-16 et à l'est par le résidu dudit lot 413-307.H t'ne partie du lot 423-308, mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur et contenant une .-uiierfirie fie 2.160 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie ilu lot 423-307.ci-haut décrite a), au sud par une partie du lot 423-309.l'ouest par des parties des lots 424-491-10 et 424-491-15 et à l'est pur le résidu dudit lot 423-308.025 1028 M.Mme/.Mr.Mrs Edgar Pilotte.née/born Arma o) t'ne partie du lu' 423-380.mesurant cettedite partie 15 |iieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une superficie de 1.005 pieds currês.mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une autre partie dudit lot 423-380, au sud par une partie du lot 423-381.ci-dessous décrite b).à l'ouest par le lot 423-365 (ruellei et à l'est par le résidu dudit lot 423-380-2.M l'ne partie du loi 423-381, mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une superficie de 2,010 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-380.ci-dessus décrite at.au sud par une partie du lot 423-3S2.à l'ouest, par le lot 423-365 (ruellel et à l'est par le résidu du lot 423-381.025-1108 m A part of lot 423-197.measuring this said part 16 fat* in width bv 07 feet in depth and containing an area of 1005 square feel, English measure and more or 'ess and \"j\"'\"'*'' as follows, to wit: on the north by a part of lot 423-196 .s above described in (o), on the south by a part of lot 42.1-1U-I.on the west bv the residue of said lot 423-197 and on the east by a part of lot 423-219.as described below in ( cadastre de la paroisse du .Sault-au-Kéeollet en la municipalité de la Cité de Montréa-Nord.De Usure irr'-gulière.Borné vers le «ud-ouest par le lot 5-28S (boulevard LangeMer) vers le nord-ouest par partie dudit lot 5-6-2 (voulevard Henri-Bourassal vers le nord-ouest par partie du lot 5-6-3 et vers le sud-est par partie du lot 5-7-2.Mesurant rent vingt pieds et soixante-huit centièmes de pied ( 120.OS', dans sa limite sud-ouest, cinquante pieds et quatre-vingt-dix->ept centièmes de pied (50. Mart.Place Bonaven- 19 09 73 turc.Montréal.70 - 7e Avenue.Lachine.10 09 73 Saint-Constant .IS 09 73 Saint-Constant.18 09 73 21.rue Principale.Saint-Jean-de- 21 00 73 Matha.Vareimes.27 08 73 101.Place Lemoyne, suite 224, 12 09 73 Longueuil.5004, rue De Cast Me, app.2, 28 09 73 Montréal-Nord.202.rue St-Antoine, Sainte-Anne-des- 03 10 73 Plaines.073.boulevard St-Joseph.Hull.12 03 73 Larouche.20 09 73 La Malbaie.12 10 73 410, rue St-Nicholas, Montréal 13 09 73 Templeton.04 10 73 25S, rue Champlain, Saint-Jean.17 09 73 0237, Albany.Brossard.28 08 73 Montreal.20 09 73 Saint-Zéphirin-de-Courval.11 09 73 5062 Hudson Crescent, Pierrefonds.24 09 73 6456 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3.1973, Vol.105, No.U Incorporation Norn / Name Siege social / Head Office BIJOUTERIE OPALE INC.\t2500, rue Contrecoeur, Montréal.\t05\t09\t73 D.BLITZER MANAGEMENT CONSULTANTS INC.CONSEILLERS EN ADMINISTRATION D.BLITZER INC.\t5730 Lockwood.Côte-Saint-Luc.\t19\t00\t73 BWSSOM CORNER FLOWER SHOPS LTD.AU COIN DES FLEURS BLOSSOM LTEE.\t1695 de Maisonneuve Boulevard West, Montreal.\t06\t09\t73 \tMontréal.\t03\t10\t73 BOUTIQUE LISI POUR ELLE INC.\t\t11\t09\t73 LA BOUTIQUE DE SOULIERS DE MELA NIE INC.M ELAN IE'S SHOE HOUTIQCE INC.\t1370 St.Catherine Street West.Montréal.\t30\t08\t73 BOUCHARD & LAMOUREUX INC.\tRoute rurale numéro 1, CP.112.Rock Forest.\t02\t10\t73 LOCATION BOVD INC.\t275 Betheny Road.Lachute.\tII\t09\t73 BRASSERIE CENTRE DU CHERCHEUR INC.\t\tni\t10\t73 BRASSERIE HARRICANA INC.\t302, route 45, Amos.\t12\t10\t73 BRASSERIE LA GARGOTE INC.\tLaval.\t25\t09\t73 LA BRASSERIE LE BRASSIN INC.\t41.St-Charles nord.Granby.\t10\t08\t73 BROSSEAU.MCKALE ET ST-GEIfMAIN INC, .\t\t28\t09\t73 CAFE RESTAURANT LA BODEGA INC.\t3450 Park Avenue.Montreal.\t30\t117\t73 CAMPING FORT ST-LOl'IS INC.\tSaint-Louis-de-F ranec.\t02\t10\t73 CAMPING LA BELLE ETOILE INC.\t\t10\t09\t73 CANTIN & FERLAND INC.\t0A.rue St-Louis, Lévis.\t09\t(0\t73 \t0107 Sherbrooke Street West.Montreal.\t12\t09\t73 CARREFOUR SAINT-HENRI INC.\tMontréal.\t25\t07\t73 CARRIERES LAVOIE & GELINAS LTEE.\t341, rue St-Olivier, Saint-Alexis-des-Monts.\t27\t09\t73 CARTIER SAFETY EQCIPMENT LTD.EQUIPEMENT DE SECURITE CARTIER LTEE.\t\t26\t09\t73 CENTRE D'ARTISANAT AU DEVIDOI INC.\t41*107.rue Chénier.Laval .\t22\t08\t73 CENTRE DE CHAUSSURES ITALIENNES LA DOR INC.\t\tU\tOS\t73 \tSaint-Bruno.\t29\t08\t73 CHATEACOVAY LEASING INC.SERVICE DE LOCATION CHATEAUGUAV INC.\t234.rue Principale, Châteauguay-Centre.\t27\t08\t73 CHIRIOTTO INC.\t1901, chemin Lac Renaud, Sainte-Adèle.\tII)\t10\t73 \t2114, route 11, Val-David, (CP.20, Sainte-Agathe).\t14\t09\t73 LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION SANTIAGO INC.SANTIAGO CONSTRUCTION CO.INC.\t1245 Sherbrooke Street West, Suite 745, Montréal.\t21\t09\t73 COMPAGNIE D'EXPLOITATION ST-EUGENE INC.\t\t24\t09\t73 COMPAGNIE DE GESTION J.A.M.INC.\t1595.rue St-Hubert, Montréal.\t06\t1)7\t73 LA COMPAGNIE DE GESTION DRAKKAR INC.\t60, rue St-Pierre, suite 100.Québec 2.\t21\t09\t73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n' U \" 6457 Incorporation Nom / Name Siège social /' Head Office Date COMPAGNIE KIRBY (QUEBEC) LTEE.KIRBY CO.(QUEBEC) LTD.LA COMPAGNIE JACK SELTZER INC.JACK SELTZER CO.INC.LES COMPTOIRS D'ABITIBI INC.O.C.COMPUTER SCIENTIFIC INC.CALCULATEUR SCIENTIFIQUE O.C.INC.LES CONFECTIONS G.A.INC.CONFECTION RODENIER INC.LES CONSTRUCTIONS C.M.D.FONTAINE INC.CONSTRUCTION H.V.E.INC.H.V.E.CONSTRUCTION INC.CONSTRUCTION L.C.M.LTEE.L.C.M.CONSTRUCTION LTD.CONSTRUCTIONS L.T.D.INC.L.T.D.CONSTRUCTIONS INC.LES CONSTRUCTIONS DUNBAR INC.DUNBAR CONSTRUCTIONS INC.CONSTRUCTION GUYMEN INC.CONSTRUCTION SIGMATECH INC.SIGMATECH CONSTRUCTION INC.LES CONSTRUCTIONS SUDIAC INC.SUDIAC CONSTRUCTION INC.LA CORPORATION D'AMENAGEMENT C.I.R.C.I.R.DEVELOPMENT CORP.LA CORPORATION D'AMENAGEMENT YARDLEY .YARDLEY DEVELOPMENT CORP.LA CORPORATION DES FACTEURS CONTINENTAL.CONTINENTAL FACTORS CORPORATION.CORPORATION DE GESTION NOVED.NOVED HOLDINGS CORPORATION CORPORATION PREM-PAY CANADA LIMITEE.PRE M-l'A Y CORPORATION CANADA LIMITED LA CORPORATION DES PROPRIETAIRES DE GITES DU QUEBEC INC.RAYMOND COURNOVER LTEE .COURTEMANCHE & PARENTEAU INC.COURTIER IMMOBILIER DE GASPE INC.CROTEAU & DUPUIS INC.LES CUISINES LAURENTIDE INC.LAURENTIDE KITCHENS INC.D.C.R.DISPLAY WORK LTD.ATELIER D'ETALAGE D.C.R.LTEE.DAIRY QUEEN DE SHERBROOKE INC.SHERBROOKE DAIRY QUEEN INC.Montreal.31 08 73 1945 Guertin, Saint-Laurent.21 09 73 Montréal.18 10 73 5450, Dudemaine.app.406, Montréal 24 08 73 390.Saint-Denis-sur-Richelieu, 06 09 73 Saint-Denis.400, rue St-Simon, Sainte-Madeleine 04 10 73 Saint-Louis-de-Pintendre.28 09 73 327.Montée de la Baie, Saint-Joseph- 24 08 73 du-Lae.4372, rue Delage, Saint-Léonard.13 09 73 98, rue Carillon, Chicoutimi-Nord.10 09 73 5333 Casgrain, Montréal.21 09 73 Saint-Michel-des-Saints.10 09 73 551 Oriole Crescent, Dorval.20 09 73 1584.rang du Fer à Cheval, Sainte- 09 10 73 Julie.Montreal.02 10 73 Montreal.05 09 73 Montreal.19 09 73 Montréal.01 10 73 1010 St.Catherine Street West, 26 09 73 Montreal Saint-Joseph de Beauce.01 08 73 815.rue St-Pierre, Saint-Joseph-de- 05 10 73 Sorel 573, rue Rosaire.Granby.28 08 73 Guspé.29 08 73 122«4, rue Grenet, Montréal .05 09 73 Montréal.26 09 73 10140, rue Hôtel de Ville, Montréal- 07 09 73 Nord Sherbrooke.04 09 73 64.58 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Norember 3.1973.Vol.105.No.U Nom / same Siège social / H tad Office WON DALBEC (1973) INC.DECORATION DE BOIS TOURNE C.& D.INC.C.4 D.TURNED WOOD DECORATION INC.DECORS ST-GEORGES INC.DESJARDINS PONTIAC BUICK INC.l'ONTIAC BUICK DESJARDINS INC.DEVAINS1ERE INC.DIMENSION PRODUCTIONS INC.PRODUCTIONS DIMENSION INC.LES DISTRIBUTIONS L'ACADIE INC.LES DISTRIBUTIONS DU III.M EURO CAN AM I.T : I EURO CANAM FILMS DISTRIBUTION LTD.DISTRIBUTIONS HAR-GAU LTEE DOLLAR!) AUTOMOTIVE PARTS LTD.PIECES AUTOMOTRICES DOI.LARD LTEE DOLLY P1NTOO COMPANY LIMITED.COMPAGNIE DOLLY PINTOO LIMITEE DOMAINE DU LAC HURON INC.DOMAINE LES CHUTES ST-GEORGES INC DOMAINE NEVEU INC.DRAPERIES LONCUEUIL INC.DUMARCO INC.DUMAS & MORIN INC.M.DUMOUCHEL INC.DUROFLAM BURNERS INC LES BRULEURS DUROELAM INC.EAU MINERALE DE LA SOURCE COLOMBIE INC.COLUMBIA SPRING MINERAL WATER INC.ECLAIRAGE VENUS INC.VENUS LIGHTING INC ECOLE DE SKI PINGOUIN INC.PENGUIN SKI SCHOOL INC.LES ENTREPRISES M.T.L.INC.LES ENTREPRISES BAZ7.INC.BA7.7.ENTERPRISES INC.LES ENTREPRISES REJEAN CHABOT INC.LES ENTREPRISES REAL CHOI NI ERE INC.Incorporation Date Montréal.2005.rue Hampton, Montréal.2S1.1ère Avenue, Saint-Georges-Est Berthier.Druiiuiiondville-Swl Montréal.1010, rue De Salalierry ouest.Monl-réal 2575 Eleurj Street East.Montreal .Saint-Hubert.1505, Dnllard Avenue.Lasalle 28 09 73 80 08 73 03 10 73 10 09 73 03 10 73 24 09 73 30 08 73 12 09 73 09 10 73 05 09 73 S09 Bclleclia-T-e Street East.Montreal 22 08 73 ENTREPRISES FORESTIERES JACQUES & FILS LTEE JACQUES A SONS FOREST ENTERPRISES LTD.LES ENTREPRISES C.FOURNIER INC.C.FOURNIER ENTERPRISES INC.174, Marie-Victorin, Longueuil.\t04\t10\t73 \t14\t00\t73 Sainte-Brigide-d'Iberville.\tni\t1\"\t73 \t21\tN\t73 1485, boulevard Désaulnierï.Longueuil\t21\t09 09\t73 78 \t31\tII.S\tlo 73 \t28\t09\t73 Montréal\t-'1\t09\t73 2705 Bates Road.Suite 104.Montréal.\t02\t10\t73 5530 Earl Road, Cote-Saint-Luc .\t17\t119\t73 389, rue St-.lérôme.Matane.\t01\tin\t73 222 - 10th Avenue.Lachine.\tIS\t011\t73 \tIC\t08\t73 12.rue Court, Granbv.\t17\t09\t73 Sa in te-Foy.\t04\tin\t73 032.Sauvageau, Thetford Mines.\t21\t09\t73 \tn\t10\t73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n' U 6459 Incorporiition Nom / Name Siège social / Head Office Date LES ENTREPRISES RAYMOND KELLY INC.\t\t31\t08\t73 LES ENTERPRISES LEBLANC & LEPAGE INC.\t\t29\t08\t73 ENTREPRISES LES TROIS TILLEULS INC.\t\t1 4\t00\t73 ENTREPRISES JACQUES PONTBRIAND LTEE.JACQUES PONTBRIAND ENTERPRISES LTD.\t\t17\t10\t73 EQUIPEMENT J.G.BRUNET INC.\t17300.Ste-Marie, Kirkland.\t03\tm\t73 EQUIPEMENTS DE BUREAU MASKOUTAIN INC.\t\t26\t09\t73 ESTIMATIONS ET DESSINS T.G.INC.\t\t07\t09\t73 EXPORTATION DE FOURRURES DE MONTREAL LTEE.MONTREAL FUR EXPORT LTD.\t\t04\tun\t73 D.J.CATTLE FARMS INC.\t2406 - 2nd Avenue.Sainte-Sophie.\t31\t08\t73 OWL FILMS LIMITED\t1247 Bishop Street.Montréal.\t14\t09\t73 FIRMACO INC.\t\t29\t08\t73 FLEURISTE STE-THERESE INC.\t5, Blainville-est, Sainte-Thérèse.\t07\t09\t73 FONDERIE D'ART ET D'ARTISANAT DU QUÉBEC INC.\t5438, boulevard Henri Bourasxa est, Montréal-Nord.\t03\t10\t73 FOURRURES SAUMUR INC.\t4529.rue Forest, Montréal-Nord.\t04\t10\t73 K.D.FURNITURE INC.MEUBLES K.D.INC.\tMontreal.\t17\t09\t73 \t410, boulevard Cartier.Laval.\t04\t09\t73 GARAGE BELLE RIVIERE INC.\t\t20\tcm\t73 GEORGES GARIEPY INC.\t\t18\t09\t73 HOTEL RAYON D'OR INC.\t693, rue Commerciale.Notre-Dame-du-Lac\t01\t1Q\t73 \tLes Méchins.\t28\t08\t73 \t3401.rue Sherbrooke est.Montréal.\t29\t08\t73 LES IMMEUBLES R.D.R.LTEE.\t\t10\t09\t73 \t\t09\tK)\t73 LES IMMEUBLES DE LA BOULANGERIE VAN HORNE INC.VAN HORNE BAKERY PROPERTIES INC.\t\t25\t09\t73 \t10800, rue Lajeunesse, Montréal.\t05\t04\t73 IMMEUBLES QUEBEC-OUEST LTEE.QUEBEC WEST REALTIES LTD.\t2892 Hardwood Boulevard, Saint-Lazare.\t12\t10\t73 IMPORTED ENGLISH WOOLENS LIMITED.IMPORTATIONS DE LAINAGES ANGLAIS LIMITEE.\t3044 St.Lawrence Boulevard.Montreal\t31\t08\t73 LES INDUSTRIES CARNAVAL DE OUEBEC INC\t\t26\t09\t73 LES INDITSTRIFS CT.AVEAT\" T.TEE\t\t03\t10\t73 LES INDUSTRIES LUCRE NE INC.LUCRE NE INDUSTRIES INC.\t170 Desrochers, Mont-Saint-Hilaire.\t04\t10\t73 LE3 INDUSTRIES PLANI-SYSTEMES INC.\t\t05\t10\t73 PLANI-SYSTEMS INDUSTRIES INC. 6460 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Nom / Same Siège social / Head Office Incorporation Date LES INVESTISSEMENTS ALANDRE INC.ALAN DRE INVESTMENTS INC.Montréal Montréal.LES INVESTISSEMENTS GERULA INC.G BRULA INVESTMENTS INC.LES INVESTISSEMENTS KORCHA LTEE.3, Place Bellerive, suite 1004, Laval.K.M.K.COMPUTER CONSULTANTS INC.222 Redfern Street.Westmount.CONSEILLERS EN INFORMATIQUE K.M.K.INC.KAUFMAN & BROAD (QUEBEC) LTEE.3400 Place Victoria, Montréal 115 KAUFMAN A BROAD (QUEBEC) LTD.L.E.S.PLASTICS INC.PLASTIQUES L.E.S.INC.LACOMBE ET VIGER INC.LAKESHORE ORTHOPAEDICS CENTRE INC.CENTRE D'ORTHOPEDIE LAKESHORE INC.JEAN-CLAUDE LAMBERT INC.REAL & LOUISE LANDRY INC.LAVEUSE D.SIMARD INC.JACQUES LA VOIE TRANSPORT INC TRANSPORT JACQUES LAVOIE INC.LESAGE ET RIOUX INCORPOREE.GILLES LEVESQUE INC.LIBRAIRIE DE L'OS INC.LA LIGUE JUVENILLE DE HOCKEY DES CANTONS DE L'EST LES LOCATIONS FERNAND PERREAULT INC N.G.LOISELLE & FRERES INC.LOMBARDl FURNITURE INC.AMEUBLEMENT LOMBARDl INC.LORDS LEASEHOLD (QUEBEC) INC.LOCABAIL LORD (QUEBEC) INC.LORD & BEAUREGARD INC.PIERRE MAINVILLE INC.MAISONS MOBILES BRONCO INC.LA MAISON MOON WAH INC.MOON WAH HOUSE INC.LES MAISONS PREFAB FRANCIS LIMITEE.MANOIR HADDON INC.H ADDON HALL INC.FERNAND MARANDA LIMITEE.R.MARCEAU ALUMINIUM INC.ALUMINIUM R.MARCEAU INC.MARCHE DE VIANDE KYDON LIMITEE.K Y DON MEAT MARKET LIMITED.21 03 73 18 09 73 19 10 73 04 09 73 25 09 73 7510 Vérité Street.Saint-Laurent.25 09 73 565, rue St-Arsène, Montréal Pointe-Claire.Sainte-Anne-des-Monts.Saint-Ambroise.385, 13e Rue.Québec.La Malbaie.325.boulevard St-Joseph.Hull.Saint-Alexandre.Coteau-du-Lac.331.Principale.Granby.800 Grand Boulevard, Chambly.Saint-Bruno.10391, Armand Lavergne, Montréal.Montreal.1952.rueBeaubienest, Montréal.623A, boulevard Iberville, Repentigny.Saint-Joachim de la Plaine, Comté L'Assomption.1206 Union Street, Montreal.Matane 800 Victoria Square, Suite 2401, Montreal.2891, boulevard Rosemont, Montréal 148, rue Clairevue est, Saint-Bruno-de-Montarville.Montréal.02 10 73 28 06 73 25 09 73 12 09 73 08 08 73 17 09 73 12 10 73 03 10 73 11 09 73 28 09 73 12 09 73 04 10 73 02 10 73 20 08 73 24 09 73 21 09 73 14 09 73 19 09 73 20 08 73 19 09 73 10 10 73 26 09 73 24 09 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n\" U 6461 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date JIMMY MARCIANO LTEE.JIMMY MARCIANO LTD.MARTI INC.MAR7.AK HOLDINGS LTD.LES GESTIONS MARZAK LTEE.ROBERT MATTE LIMITEE.METROPOLITAN VALVE REBUILT INC.RECONSTRUCTION DE VALVES METROPOLITAIN INC.MIDLAND DEVELOPMENT INC.LES AMENAGEMENTS MIDLAND INC.MINES DUBEL INC.DVBEL MINES INC.MONTAV AUDIO VISUAL SERVICES LTD.SERVICES AUDIOVISUELS MONTAV LTEE.MONTREAL GIFTS «{\u2022 GADGETS SHOPS INC.BOUTIQUES DE CADEAUX ET DE GADGETS MONTREAL INC.MONTREAL SHUTTLE SERVICE LTD.LES SERVICES DE NAVETTE DE MONTREAL LTEE.MOTEL JOLIETTE INC.MOTEL DU PARADIS INC.MOTO SPORT POIRIER INC.THOMAS MUNKITTRICK INC.MURPHY-BREHAUT HOLDINGS LIMITED.GESTION MURPHY-BREHAUT LIMITED.FRANCOIS NOLIN (INTERPROVINCIAL) LTEE.PAY & CHANG INC.PILON & CHARRON INC.PLACEMENT B.V.M.LTEE.B.V.M.INVESTMENT LTD.PLACEMENTS G.M.O.QUEBEC INC.LES PLACEMENTS GRAND CALUMET INC.PLACEMENTS MIROLIE INC.LES PLACEMENTS DE LA PENINSULE LIMITEE.PLACEMENTS TEMIS INC.PLACEMENTS TRIANGLE D'OR INC.LA PLAINE AUTO PARTS INC.PIECE D'AUTO LA PLAINE INC.PLOMBERIE ALLAIRE & FILS INC.PORTES DE GARAGE NADEAU INC.NADEAU GARAGE DOORS INC.\t14\t09\t73 5126, rue Henri-Bourassa est, Mont-\t06\t07\t73 réal-Nord.\t\t\t Suite 612, 800 Victoria Square, Mont-\t26\t09\t73 real 115.\t\t\t \t24\t09\t73 \t02\t10\t73 1245 Sherbrooke Street West.Mont-\t21\t09\t73 real.\t\t\t \t14\t09\t73 5025 McDonald Street.Apt, 208.Mont-\t28\t08\t73 real.\t\t\t 2071 St-Louis, Saint-Laurent.\t24\t09\t73 1553, Marie Claire.Lasalle.\t20\t09\t78 2070, Visitation, Saint-Charles-Borro-\t21\t02\t73 mée.\t\t\t 24, rue Rouville.Saint-Jean-Baptiste de\t24\t08\t73 Rouville.\t\t\t 1405, route Port St-François, Saint-\t01\t10\t73 Jean-Baptiste-de-Nicolet.\t\t\t \t02\t10\t73 536, 88th Avenue, Laval.\t02\t10\t73 \t01\t10\t73 \t19\t07\t73 \t16\t05\t73 \t21\t09\t73 \t21\tos\t73 Sept-Iles.\t26\t09\t73 130, le Avenue, Rougemont.\t26\t09\t73 \t05\t10\t73 \t06\t10\t73 \t10\t07\t73 \t10\t09\t73 7, rue Bretagne, Beauport.\t02\t10\t73 11760, rue Bossuet, Montréal-Nord-\t03\t10\t73 6462 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.November 3.1973.Vol.10-ï.No.U _ PRIMESCO INC.CP.PRINTING INC.LES PROMOTIONS V-M CHAMPLAIN INC LES PROMOTIONS V-M HULL INC.LES PRODUCTIONS AGRICOLES B.D.M.LIMITEE.LES PRODUCTIONS JACQUES GAGNE INC.LES PRODUCTIONS HENRI STADT LTEE HENRI STADT PRODUCTIONS LTD.LES PRODUITS DE CUIR UNIQUE INC.UNIQUE LEATHER GOODS INC.PROGRESSIVE MACHINE WORKS OF CANADA LTD.ATELIER DE MACHINERIE PROGRESSIVE DU CANADA LTEE.PUBLICATIONS FAX INC.FAX PUBLISHING INC.PUBLICATIONS PAVARC INC.QUEBEC LAND RESEARCH CORPORATION LA CORPORATION DE RECHERCHES EN TERRAINS QUEBEC QUINCAILLERIE L.M.S.INC.REMBOURRAGE DENIS INC.LES REMORQUES HILL INC.HILL TRAILERS INC.RESSORTS ABITIBI INC.ABIT1HI SPRINGS INC.RESTAURANT DELICES BAR-B INC.BARB DELIGHT RESTAURANT INC.LE RESTAURANT DU JOYEUX DRAGON LTEE HAPPY DRAGON RESTAURANT LTD.LA ROBE DU QUEBEC (1973) INC.RONDES INC.ROYRAD INC.S.A.F.CONSTRUCTION (1973) INC.CONSTRUCTION > A I' (1973) INC S.I.NEMIROFF & ASSOCIES INC.S.I.NEMIROFF A- ASSOCIATES INC.ST.CATHERINE HOLDINGS LTD.LES GESTIONS STE-CATH Ell IN E LTEE.SECURITE CANA LTEE.CAN A SAFETY LTD.SERGE & CLAUDE INC.892S.boulevard St-Michel.Montréal.24 09 73 Montreal.1» 0» 72 1094.Marquette.Longueuil .14 09 73 125.rue Laurier.Hull.25 09 73 New-Richmond.03 10 73 10800, Lajeunesse, Montréal.12 09 73 1180 St.Antoine Street.Room 300.03 10 73 Montreal.10221 St.Lawrence Boulevard, Mont- 07 09 7 3 real.40 Bates Road.Outremont .04 10 73 Montréal.19 09 73 10.rue St-Jacques ouest, Montréal.27 09 73 Montreal.17 09 73 1245, Suzor Coté, Sillery.Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham.Anjou.402.4e Avenue est.Amos Brossa ni .Verdun.L'As»omption.Notre-Dame-du-Lac.Trois-Rivières.Saint-Henri.SERVICE D'EDIFICE ATLAS LTEE .ATLAS BUILDING SERVICES LTD.1115 Sherbrooke Street West.Suite 2302, Montreal.1254 Stanley Street, Montreal 325.rue Hodge, Saint-Laurent 280, boulovurd Fort St-Louis, Centre d'Achat « La Seigneurie », Boucherville.1255 Phillips Square, Suite 911.Montreal.02 10 73 17 09 73 03 10 73 01 10 73 31 08 73 19 09 73 27 09 73 04 10 73 27 09 73 28 09 73 21 09 73 14 09 73 16 10 73 24 08 73 19 09 73 Incorporation Komi Name Siège social / Head Office Date GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1973.105' année.n° U 6463 Incorporation Nom / Name Siège social / Head Office Date SERVICES D'ENTRAIDE MUTUEL DE MONTREAL INC.MONTREAL MUTUAL HELP SERVICES INC.\t4453, rue Beaubien, app.5, Montréal\t21\t09\t73 LES SERVICES D'EQUIPEMENT D'ALARMES & DE TELEPHONES M.C.INC.M.C.ALARM & TELEPHONE EQUIPMENT SERVICES INC.\t8877 St.Lawrence Boulevard.Montreal.\t21\t1)9\t73 SERVICE D'INFORMATION CITADEL INC.\t\t21\t08\t73 CITADEL COMPUTER SERVICE INC.\t\t\t\t SERVICE DE MIRAGE METROPOLITAIN INC.\tMontréal.\t03\t10\t73 SERVICES SANITAIRES SHERBROOKE INC.\tShrbrooke.\t28\t09\t73 SANITARY SERVICES SHERBROOKE INC.\t\t\t\t SIMILAUN PROPERTIES LTD.LES IMMEUBLES SIMILAUN LTEE.\t1155 Dorchester Boulevard West.Suite 818.Montreal 102.\t28\t09\t73 SOCIETE D'ADMINISTRATION S.M.G.D.INC.\t\t13\t09\t73 \tMontréal.\tU\t09\t73 STVROJET INC.\t34, Côte de la Fabriue, Québec.\t02\t10\t73 SUPER MARCHE LEFORT INC.\t\t28\t0!)\t73 \t4, avenue Sunset, Outremont.\t09\t10\t73 T.A.HOLDINGS LTD.LA COMPAGNIE DE PORTEFEUILLE TA.LTEE\t015 Dorchester Boulevard West.Suite 820, Montreal 101.\t20\t09\t73 TABAGIES DYNAMIQUES INC.\t4420, rue des Cyprès, Orsainville.\t02\t10\t73 TABAGIE STE-ADELE INC.\tG9, rue Morin, Sainte-Adèle.\t¦8\t09\t73 TERRACES S00 INC.\t630 Dorchester Boulevard West.Montreal.\t26\t09\t73 LES TEXTILES ALAMANDA LIMITEE.ALAMANDA TEXTILES LIMITED.\t615 Dorchester West, Suite 1010, Montreal.\t25\t09\t73 TISSUS & TAPIS MADAME ROY JONQUIERE INC.\t\t09\t10\t73 TITAN ICE TIME PRODUCTS INC.SERVICE D'EQUIPEMENT DE SPORTS D'HIVER TITAN INC.\t2411 Lac Renaud Street, Sainte-Adèle.\t18\t09\t73 TRANSPORT DODO INC.\t381A, Montée Sanrhe, Sainte-Thérèse-Ouest.\t05\t09\t73 TRANSPORT ROBERT (QUEBEC) 1973 LTEE.ROBERT TRANSPORT (QUEBEC) 1973 LTD.\t130, 1ère Avenue, Rougcmont\t26\t09\t73 TRANSPORT ROBERT (1973) LTEE.ROBERT TRANSPORT (lù?j) LTD.\t130, 1ère Avenue.Rougemont.\t26\t09\t73 GEORGES TSOUKALAS INC.\t55, Place I.asalle, Baie-Comeau.\t1 1\t09\t73 VALIBF.C INC.\t186, rue Chopin.Châteauguay-Centre,\t25\t09\t73 VOYAGES LOGAN, GASPE, INC.\tGnspé.,.\t20\t08\t73 WOLDAM ADMISISTRATION LTD.L'ADMINISTRATION WOLDAM LTEE\t1498 Stanley Street, Montreal.\t28\t09\t73 54295-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.64295-0 Pierre Desjardins.Director of the Companies Service. 6464 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Xnrembrr 3.1973.Vol.105, Xn.j j Lettres patentes (3' partie) Letters Patent (Part III) Le ministre des institutions financières, compagnies e: coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des let 'res patentes constituant en corporation: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III of the Companies Act.he has granted letters patent incorporating: Nom / .Vamc Siège social / H tail Office Incorporation Date AGENCE QUEBEC INTERNATIONAL INC.L'ASSOCIATION DES HANDICAPES DE LA CHAUDIERE.ASSOCIATION HELLENIQUE DES PARENTS GRECS-ORTHODOXES DE L'ECOLE SECONDAIRE BYRON BYNG.(JREEK ORTHODOX H ELLES IC ASSOC I AT IOS OF PARESTS OF BYRON BY NO HIGH SCHOOL ASSOCIATION (HELLENIQUE) DES PARENTS GRECS-ORTHODOXES DE L'ECOLE SECONDAIRE MONTREAL GREEK ORTHODOX (HELLESIC) ASSOCIATION OF PARESTS OF MONTREAL HIGH SCHOOL.ASSOCIATION (HELLENIQUE) DES PARENTS GRECS-ORTHODOXES DE L'ECOLE SECONDAIRE OUTREMONT.GREEK ORTHODOX (HELLENIC) ASSOCIATION OF PARENTS OF OUTREMONT HIGH SCHOOL.ASSOCIATION DES HOMMES D'AFFAIRES HI MAIL ST-ROCH INC.ASSOCIATION DES MARCHANDS DE PLACE FRONTENAC INC.LE CENTRE DE DIRECTION LANSDOWNE.THE LANSDOWNE TUTORING CENTER.CENTRE FAMILIAL DE VACANCES DU LAC DES QUINZE.CENTRE PLEIN AIR TERRE ROUGE INC.CERCLE DES AFFAIRES RICHMOND-MELBOURNE.LE CERCLE DE L'AGE D'OR DE LES BOULES.INC.CLINIQUE DE PROTHESES DENTAIRES ST-HUBEHT INC.LE CLUB DE L'AGE D'OR DE ST-FRANÇOIS D'ASSISE.CLUB DE L'AGE D'OR DE ST-PIE-X.CLUB D'AGE D'OR ST-PIERRE DE TASCHEREAU.LE CLUB DE L'AGE D'OR ST-PROSPER INC.LE CLUB DE BASEBALL AIGLES JUNIOR DE TROIS-RIVIERES INC.CLUB DE M OTONEIGE LOUPS DES PRAIRIES INC.CLUB OPTIMISTE BOIS DES FILION.QUEBEC INC.THE OPTIMIST CLUB OF BOIS DES FILION.QUEBEC INC.CLUB OPTIMISTE DE MARIEVILLE INC.LE CLUB RECREATIF GASPESIEN INC.CLUB SOCIAL DU LAC BAUBLE GAG NON VILLE INC.Montréal.'5 10 73 Saint-Georges de Beauce- 24 05 73 Montréal.04 10 73 Montréal 05 10 73 Montréal.05 10 73 Québec.09 10 73 2600.Ontario est, Montréal.28 09 7 3 630 Dorchester Boulevard West.03 07 73 Montreal.Angliers.10 10 73 Saint-Nicolas.12 10 73 Richmond .04 10 73 Les Boules.14 09 73 5150, St-Hnbett.Montréal.10 07 73 Saint-François-d'Assise.04 07 73 Paspébiac.04 10 73 Taschereau ., 27 09 73 Saint-Prosper.04 10 73 1835, rue Victoria, Trois-Rivières.12 07 73 S, rue Legault, Mercier.21 OS 73 Bois-des-Filion.04 09 73 Marieville.22 06 73 16, rue Viau, Saint-Isidore.13 00 73 Lac Barbie, Gagnon-Ville.28 09 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n' U 6465 Nom / Name Siège social / Head Offic Incorporation Date CLUB SPORTIF CHASSE & PECHE D'ALBANEL INC.CLUB DU TROISIEME AGE DES DEUX-MONTAGNES INC.LA CORPORATION DU CONSEIL DES CITOYENS DU MONDE AU QUEBEC INC.FONDATION DES AINES DU QUEBEC.SENIOR CITIZENS FOUNDATION OF QUEBEC.GARDE DE LASCENSION INC.GARDE ST-BERNARDIN DE WATERLOO INC.GARDE ST-BONIFACE INC.GARDE ST-CYRILLE DE LESSARD INC.GARDE ST-CYRILLE DE NORMANDIN INC.GARDE ST-DENIS-SUR-RICHELIEU INC.GARDE ST-JEAN BAPTISTE DE ST-GEDEON INC.GARDE ST-PATRICE DE M AGOG INC.LES JOUVENCELLES DE P.A.T.INC.LES PRESSES COLLEGIALES DE JONQUIERES INC.SERVICES COLLECTIFS DES ETUDIANTS DU COLLEGE DE SAINTE-FOY.SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ARTS (S.D.A.).UNION REGIONALE DES GARDES PAROISSIALES DU SAGUENAY-LAC ST-JEAN INC.Albanel.17 09 73 316, 4e Avenue, Deux-Montagnes.21 09 73 Montréal.21 09 73 Montréal.10 07 73 L'Ascension-de-Patapédia.26 09 73 Waterloo.26 09 73 Saint-Boniface-de-Shawinigan.26 09 73 Saint-Cyrille-de-Lessard.26 09 73 Normandin.26 09 73 Saint-Denis.26 09 73 Saint-Gédéon.2G 09 73 Magog.26 09 73 11884.rue Ste-Catherine, 20 09 73 Pointe-aux-Trembles.Jonquière.17 09 73 2410.chemin Ste-Foy, Sainte-Foy .14 09 73 Montréal.31 08 73 Dolbeau.26 09 73 Le directeur du service des compagnies, 54295-o Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins.54295-0 Director of the Companies Service.Lettres patentes supplémentaires\tSupplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the il a accordé des lettres patentes supplémentaires h: Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes A LLP A K (QUEBEC) LIMITED.ALLPAK (QUEBEC) LIMITEE ASBESTONOS CORPORATION LIMITED.LES ASSURANCES LEGAULT & CLAUDE INC.BOUTIQUE L'ANTARES LTEE.28 04 67 19 09 73 Modifiant le capital I Altering the capital .29 09 28 17 09 73 Modifiant le capital / Altering the capital 04 01 73 16 10 73 Ancien nom 1 Former name: LEGAULT, CHOUINARD & CLAUDE INC.14 OG 73 12 10 73 1) Ancien nom / Former name: BRASSERIE NOTRE-DAME LTEE 2) Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 6466 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Nom / .Vame Incorporation L.P.S./ s.L.P.Date Date PIERRE BRETON INC.CENTRE COMMUNAUTAIRE MELKITE DE SAINT-SAUVEUR (MONTREAL) 31 01 60 CLINIQUE OBSTETRICALE ET OVNECOLO- 09 0J 73 GIQUE GUIMOND INC.CONSTRUCTION DASTOUS & GELINA8 LTEE D'ASTOUS .(\u2022 GELINAS CONSTRUCTION LTD.LES CONSTRUCTIONS PIEDMONT INC.PIEDMONT CONSTRUCTION INC.COURTAGE GRAVEL LTEE.GRAVEL FORWARDING LTD.OS 07 73 30 12 08 F.R.DALLAIHE INC.21 02 61 EQUIPEMENT PIEDMONT LTEE.28 12 71 PIEDMONT EQUIPMENT LTD.G.B.M.CONSTRUCTION INC.24 05 72 CONSTRUCTION G.B.M.INC.GARAGE NICOL INC.21 03 69 LA GARDE PAROISSIALE DE BAIE-COMEAU INC.22 04 64 LA GARDE PAROISSIALE DE JONQUIERE 17 02 65 INC.GAR-LAN LEASING 'QUEBEC) LTD.30 11 72 LOCATION GAR-LAN (QUEBEC) LTEE IMMEUBLES ALFRED DALLAIRE INC 24 08 61 LES INDUSTRIES CARDIN LIMITEE CARDIN INDUSTRIES LIMITED 10 06 69 J.E.KEAVS LTEE.01 08 49 MANOIR CLAIRVAL (LATERRIERE) LTEE 02 10 63 A.MARTEL A FILS LTEE.27 11 61 MOTEL TROIS PISTOLES INC.31 07 72 Modification) Changes 27 04 72 17 10 73 Etendant les pouvoirs I Extending the poteen 17 07 73 Augmentant la valeur des biens immobiliers / Increasing the value of the immoveable property 20 09 73 Ancien nom / Former name: CLINIQUE OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIQUE GUIMOND INC.02 11 62 10 09 73 Ancien nom / Former name: G.& W.CONSTRUCTION LIMITEE 01 10 73 Modifiant le capital / Altering Ike capital 21 09 73 Ancien nom / Former name: LES PLACEMENTS LIONEL GRAVEL INC.LIONEL GRAVEL INVESTMENTS INC.18 10 73 Etendant les pouvoirs / Extendingthc powers 25 09 73 Modifiant les dispositions des lettres pa- tentes / Amending the provisions of the letters patent 12 10 73 Ancien nom / Former name: entreprises g.l.m.inc.g.l.m.enterprises inc.20 09 73 1) Ancien nom / Former name: NICOL MARINE INC.2) Etendant les pouvoirs/Extending the powers 26 09 73 1) Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 2) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes A mending certain provisions of the letters patent 26 09 73 1) Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 2) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / -4 mending certain prolisions of the letters patent 25 09 73 Modifiant le capital / Altering the capital 16 07 73 U Ancien nom / Pormrr name.LES IMMEUBLES FUNERAIRES ALFRED DALLAIRE INC.2) Modifiant le capital / Altering the capital 3) Modifiant les dispositions des lettres pa- tentes / Amending the provisions of the letters patent 21 09 73 1) Etendant les pouvoir- Extending th.;«-.-wers 2) Modifiant le capital / Altering the capital 09 10 73 Modifiant le capital/ Altering Oit capital 12 M) 73 Ancien nom / Former name: MANOIR CLAIRVAL (1963) LTEE 24 09 12 10 73 Modifiant le capital / Altering the capital 73 Ancien nom / Former name: MARTEL 4 FILS LTEE GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1973, 105' année, n\" U 6467 Nom I Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes P.L.N.INC.18 11 71 NORMICK PERRON INC.30 04 68 LES PLACEMENTS LIONEL GRAVEL INC.30 12 68 LIONEL GRAVEL INVESTMENTS INC.POLYCLINIQUE GRAVEL INC.03 05 62 RAYLAND INC.06 06 72 PHILIPPE ROY TRANSPORT INC.15 02 08 12 10 73 Etendant les pouvoirs .' Extending the powers 02 10 73 Modifiant le capital / Altering the capital 20 Oil 73 Etendant les pouvoirs / Extending the powers 04 0!) 73 Modifiant le capital / Altering the capital 05 09 73 Ancien nom / Former name: CREATIONS LYDIA INC.SOCIETE GAZIFERE DE HULL INCORPOREE TREMBLAY & FILS (ROUYN) INC.TWENTIETH CENTURY HOLDINGS CORPORATION CLAUDE VERTEFEUILLE INC.VOYAGES J.B.L.INC.J.B.L.TRAVEL INC.06 09 73 I) Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 2) Modifiant certaines dispositions des let- tres patentes / Amending certain provisions of the letters patent 3) Modifiant le nombre des administra- teurs / Changing the number of directors 27 12 56 24 09 73 Modifiant le capital / Altering the capital 07 05 65 04 07 73 Modifiant le capital / Altering the capital 24 01 63 12 10 73 Etendant les pouvoirs / Extending the powers 12 02 62 26 07 73 Ancien nom / Former name: J.A.JULIEN INC.10 07 73 21 08 73 Modifiant le capital,' Altering the capital Le directeur du serpice des compagnies, 54295-u Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 54295-0 Director of the Companies Service.Abandon de charte\tSurrender of Charter Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de la charte de:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has accepted the surrender of the charter of: Nom / Xame\tIncorporation Dissolution Date Date CHEZ ALEXANDRA (LONGUEUIL) INC.LA COMPAGNIE DE TELEPHONE DE LA PETITE NATION.LA COMPAGNIE DE TELEPHONE DE RONTON INC.THE ROXTON TELEPHONE COMPANY INC.DOMAINE IDEAL INC.DRESS & SPORTSWEAR CONTRACTORS ASSOCIATION OF QUEBEC.ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN ROBES & VETEMENTS SPORTS DU QUEBEC.DUNHAM CREAMERIES INC.EDSA ENTERPRISES LIMITED.LES ENTREPRISES NARO LTEE.NARO ENTERPRISES LTD.04\t01\t67\t09\t11\t73 12\t06\t02\t02\t11\t73 29\t07\t66\t1)0\t11\t73 17\t12\t64\t00\t11\t73 os\t04\t71\t09\t11\t73 (6\t02\t55\t02\t11\t73 01\t02\t60\t02\t11\t73 11\t00\t61\t09\t11\t73 6468 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Nom / Name JAMIR TRAILER PARK LTD.KNIT ALIA (INTERNATIONAL) ING.KRON INVESTMENTS LTD.MILCOR HOLDINGS INC.MOKAR DEVELOPMENT CORPORATION.NICHOLS DEVELOPMENT CORP.LA PIERRE DE TAILLE ARCHAMBACLT LIMITEE ARCHAMBAULT CUT STONE LIMITED.LAURENTIAN COATINGS INC.ROYALGAZ LTEE.ROYALGAS LTD.SAM RASSIE LINGERIE INC.SILVER GRANITE INDUSTRIES LTD.SOCIETE DE GESTION PONTLIEU INC.SODEX LIMITEE.SUNBAR REALTIES LTD.SUNSET DEVELOPMENT CORPORATION.TREITEL CORPORATION.VILLA ROSA DES DEUX MONTAGNES INC.Incorporation Date 29 12 67 Dissolution Date 21\t08\t58\t02\t11\t73 24\t04\t70\t00\t11\t73 10\t04\t58\t09\t11\t73 27\t12\t67\t09\t11\t73 11\t07\t66\t09\t11\t73 26\t04\t67\t09\t11\t73 27\t02\t51\t09\t11\t73 \t\t03\t66\t09\t11\t73 \t\t12\t68\t09\t11\t73 \t\t02\t65\t09\t11\t73 \t\t01\t65\t09\t11\t73 09 11 73 21\t10\t68\t09\t11\t73 30\t05\t56\t09\t11\t73 31\t07\t62\t07\t09\t73 05\t07\t62\t02\t11\t73 22\t01\t59\t02\t11\t73 07\t08\t56\t09\t11\t73 29\t05\t57\t09\t11\t73 20\t07\t71\t09\t11\t73 54295-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.54295-o Pierre DESJARniNs, Director of the Companies Service.Fusion de compagnies Amalgamation of companies Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes autorisant la fusion de: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted letters patent authorizing the amalgamation of: Nom de la nouvelle compagnie Xame of new company Siège social Head office Fusion Amalgamation Date Nom des compagnies fusionnées A ames of companies amalgamated ENTREPRISES COULOMBE LTÉE.Québec.01 10 73 ALEX COULOMBE LTÉE CLAIRE FONTAINE QUÉBEC LIMITÉE.54295-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.54295-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, »° U 6469 Changement de nom Change of Name Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a approuvé les règlements de changement de nota suivant:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act.he has approved the by-laws changing the name of: Nouveau nom / New name\tAncien nom Incorporation Former name Date ALLEN & FUGERE INC.ALLEN & HAYES INC.28 09 62 PAUL ARNO SALES LTD.FIBREMOULD PRODUCTS LTD.19 12 69 LES VENTES PAUL ARNO LTÉE.CLUB DE NATATION SAINT-LAURENT INC.CLUB DE COMPÉTITION DE NA- 06 03 73 TATION SAINT-LAURENT INC.LES COUVERTURES IDÉALES INC.LES COUVERTURES IDÉALES 02 05 66 (1966) INC.IDEAL ROOFING (196C) INC.MENNITI & FRERES INC.MOUNT ROYAL MUNICIPAL ASSOCIATION INCORPORATED.L'ASSOCIATION MUNICIPALE DE MONT-ROYAL INCORPORÉE.MENITTI & FRERES INC.20 03 73 MOUNT ROYAL PROPERTY 16 03 66 OWNERS' ASSOCIATION INC.L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE MONT-ROYAL INC.UNIMEDIA INC.LES PRESSES UNIES INC.23 08 73 54295-0 Le directeur du service des compagnies.Pierre Desjardins.54295-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Change of name \u2014 Applications Act Henry A.Gedziorowski Avis est donné, par les présentes, que Henry A.Gedziorowski, ingénieur, domicilié au 3447, avenue King Edward, à Montréal, district de Montréal, présentera une requête au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom pour celui de Henry A.Gordon.Montréal, ce 27 octobre 1973.Les procureurs du requérant, Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard.54268-43-2-0 Mahler, Montgomery & Renault.Henry A.Gedziorowski Notice is hereby given that Henry A.Gedziorowski, engineer, domiciled at 3447 King Edward Avenue.City of Montreal.District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing his name to Henry A.Gordon.Montreal, October 27, 1973.Ogilvy.Cope, Porteous.Hansard, Mauler.Montgomery & Renault.54268-43-2-0 Attorneys for petitioner.Stephen Irwin Silverstein Avis est donné que Stephen Irwin Silverstein, étudiant, de Ville St-Michel, district de Montréal, et y demeurant au 7631.24e Avenue, s'adressera au ministre de la justice afin de faire changer son nom en celui de Stephen Irwin Gray.Montréal, le 19 octobre 1973.Le procureur du requérant, 54270-43-2 Milton L.Klein, c.r.Stephen Irwin Silverstein Notice is given that Stephen Irwin Silverstein.student, of the City of St.Michel.District of Montreal, therein residing at 7631 -24th Avenue, will petition the Honourable Minister of Justice for the change of his name to Stephen Irwin Gray.Montreal, October 19th.1973.Milton L.Klein, q.c, 54270-43-2-o Attorney for petitioner. 6470 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Eméa Charestte Avis est donné que Eméa Charestte domiciliée au 3146 France Prime, appartement 210, Ste-Foy.Quebec 10, s'adressera au ministre de la justice afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Eméa Charest.54264-43-2-0 Eméa C'iiarest-Di bê.Emca Charestte Notice is given that Eméa Charestte, domiciled at 3146 France Prime.Apartment 210, Ste.Foy, Québec 10, will apply to the Minister of Justice for an order changing her name to that of Eméa Charest.54264-43-2 Eméa Chahest-Dubê.William Albert Cockill Avis est par les présentes donné que William Albert Cockill.résidant et domicilié au 8085 rue Roux, dans les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, pour obtenir un décret changeant son nom de William Albert Cockill à celui de William Albert Taylor, ledit changement de nom devant aussi concerner son épouse Jean Neil Murray et ses enfants Margaret et Rosaland.Montréal, ce 16 octobre 1973.Le procureur du requérant.54266-43-2-0 Norman S.Kessner.William Albert Cockill Notice is hereby given that Mr.William Albert Cockill residing and domiciled at 8085 Roux Street, in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from William Albert Cockill to William Albert Taylor, said change of name will also benefit to his wife Jean Neil Murray and his children Margaret and Rosaland of the same address.Montreal.October the 16th, 1973.Norman S.Kessner.lawyer.54266-43-2-0 Attorney for the Petitioner.Iniioceiizo Conaentlno Avis est donné que Innocenzo Cosenlino, domicilié et résidant au 3274 Jean Rivanl, dans les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom de Innocenzo Cosentino en celui de Vincent Cosentino.Montréal, ce 18 octobre 1973./.« procureur du requérant, 54267-43-2-0 Me Alain André.Innocenzo Conscntino Notice is hereby given that Innocenzo Cosentino, domiciled and residing at 3274 Jean Rivanl, in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from Innocenzo Cosentino to Vincent Cosentino.Montreal.October the 18th, 1973.Me Alain André, 54267-43-2-0 Attorney for the Petitioner.Marian Gedziorowski Avis est donné, par les présentes, que Marian Gedziorowski, représentant pour les ventes d'automobiles, domicilié au 3447, avenue King Edward, à Montréal, district de Montréal, présentera une requête au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom pour celui de Marian Gordon.Le nom de sa femme est Henrietta Lato.Montréal, ce 27 octobre 1973.Les procureurs du requérant, Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, 54269-43-2-0 Marler.Montgomery & Renault.Marian Gedziorowski Notice is hereby given that Marian Gedziorowski.car sales representative, domiciled at 3447 King Edward Avenue, City of Montreal, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing his name to Marian Gordon.His wife's maiden name is Henrietta Lato.Montreal.October 27.1973.Ogilvy.Cope.Porteous, Hansard, Mahler.Montgomery & Renault, 54269-43-2-0 Attorneys for petitioner.Walter Michael Chapates Avis est donné qu'une requête en changement de nom sera présentée au ministère de la justice par monsieur Walter Michael Chapates, superviseur, domicilié à 8897 boulevard LaSalle.apt.122.afin de changer son nom de famille de Chapatcs pour celui de Chapatis.le tout en conformité avec la Loi du change-de nom.1965, S.Q., chapitre 17.Le notaire, 54356-44-2-o Clément Lamarre.Walter Michael Chapates Notice is hereby given that Mr.Walter Michael Chapatcs, Foreman, residing at 8897 LaSalle Boulevard, Apt.122.in the City of LaSalle.will present an application to the Minister of Justice for the purpose of obtaining an order of the Lieutenant-Governor in Council changing his name from Chapates, to Chapatis, the whole in conformity with the Change of Name Act, 1965, S.Q., chapter 77.Clément Lamarre, 54356-44-2-0 Notary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n° U 6471 Michael Chelpa Avis est par la présente donné que Michael Chelpa, résidant et domicilié au No 2140, rue Labelle, App.11, à Longueuil, district de Montréal, demandera au ministre de la justice de changer son nom à Michael Helpin.lœs procureurs du requérant, Pilon, Ferraki, 54265-43-2-0 Braconnier et Larivière.Michael Chelpa Notice is hereby given that Michael Chelpa, residing and domiciled at civic number 2140 Labellc Street, Apt.11, in Longueuil, district of Montreal, will make application to the Minister of Justice to have his name changed to Michael Helpin.Pilon, Ferrari, Braconnier et Larivière, 54265-43-2-0 Attorneys for Petitioner.Diane Couture Diane Couture, secrétaire, résidant et domiciliée au 6030 Des Érables, dans les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom de famille de Couture à Binette.Montréal, le 25 septembre 1973.Les procureurs de la requérante.St-Louis-Labelle, Lafontaine, 54357-44-2-0 & Charbonneav.Diane Couture Diane Couture, secretary, residing and domiciled at 6030 Des Érables, in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing her name to that of Diane Binette.Montreal, September 25th, 1973.St-Louis-Labelle, Lafontaine, & Charbonneau.54357-44-2-0 Attorneys for petitioner.Anthony Czepaitis Avis est donné qu'une requête en changement de nom sera présentée au ministère de la justice par monsieur Anthony Czepaitis, préposé à la réception, domicilié à 336, 7e Avenue, à LaSalle, afin de changer son nom de famille de Czepaitis pour celui de Chapatis, le tout en conformité avec la Loi du changement de nom, 1965, S.Q., chapitre 17.Le notaire.54358-44-2-0 Clément Lamarre.Anthony Czepaitis Notice is hereby given that Mr.Anthony Czepaitis.receiver, residing at 336, 7th Avenue, in the City of LaSalle, will present an application to the Minister of Justice for the purpose of obtaining an order of the Lieutenant-Governor in Council changing his name from Czepaitis, to Chapatis, the whole in conformity with the Change of Name Act.1965, S.Q., chapter 77.Clément Lamarre, 54358-44-2-0 Notary.Daniel Fournier Nous donnons avis que Daniel Fournier, commis, domicilié au 4624, rue Lebert.cité de Laval, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom pour celui de Daniel Lavertu.Montréal, le 26 septembre 1973.Les procureurs du requérant, Gonthier, Barrière & 54359-44-2-0 & Charbonneav.Daniel Fournier Notice is given that Daniel Fournier, clerk, domiciled at 4624 Lebert Street, City of Laval, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Daniel Lavertu.Montreal, September 26, 1973.Gonthier.Barrière & Charbonneav.54359-44-2 Attorneys for applicant.Ernest Verret Avis est donné que Ernest Verret, administrateur, domicilié et résidant au 201, Marquis de Tracy, Boucherville, province de Québec, s'adressera au ministre de la justice pour l'obtention d'un décret changeant son nom en celui de Ernie King; ce changement sera également applicable à son épouse, née Aima Sicard et à ses enfants mineurs Michel, Linda et Elizabeth, de la même adresse.Daté à Montréal, le 19 octobre 1973.Les procureurs du requérant.Desjardins, Ducharme, Desjardins.54361-44-2-0 Tellier, Zioby & Michaud.Ernest Verret Notice is given that Ernest Verret, director, residing and domiciled at 201 Marquis de Tracy, Boucherville, Province of Québec, will apply to the Minister of Justice to obtain an order changing his name to that of Ernie King; such change will also benefit his wife, née Alma Sicard.and his minor children Michel, Linda and Elizabeth of the same place.Dated at Montreal, this 19th day of October, 1973.Desjardins, Ducharme, Desjardins, Tellier, Zigby & Michaud, 54361-44-2-0 Attorneys for applicant. 6472 QUE.It EC OFFICIAI.GAZETTE, November ¦?.I97J.1\"»/.So.jj Anne Morrine Smith Avis est par la présente donné que Anne Morrine Smith, demeurant au 1737 rue Sanguinet, Montréal, province de Québec, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil d'émettre un décret changeant son nom en celui de Anne Morrine Gamer.Montréal, le 11 octobre 1973.Les avocats de la requérante.54360-44-2-o Jacobs & Tannenbai m.Anne Morrine Smith Notice is hereby given that Anne Morrine Smith, residing at 1737 Sanguinet Street, in Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing her name to Anne Morrine Garner.Montreal, October 11.1973.Jacobs & Tannenbaum, .\">4360-44-2-o Attorneys for applicant.itrenislaiis czepaiies.Avis est donné qu'une requête en changement de nom sera présentée au ministre de la justice par M.Hrenislaus Czepaiies.Outillrur.domicilié à 4030.13c Avenue, Laval Ouest.Ville de Laval, afin de changer son nom actuel de Hrenislaus Czepaiies.pour celui de Rronnie Chapatis, le tout en conformité avec la Loi du changement de nom 1905 S.Q.chap.77.I.e notaire.54395-44-2-0 Clément Lamakiie.Brenislau* Czepaiies Notice is hereby given that Mr.Brenislaus Czepaiies.Die mixer, residing at 4030.13th Avenue.Laval West.Town of Laval, will present an application to tin-Minister of Justice for the purpose of obtaining an order of the Lieutenant-Governor in Council changing Ilia name from Hrenislaus Czepaiies, to lironnie Chapatis, the whole in conformity with the change of name Act 1965, S.Q.Chapt.77.Clément Lamakkk, 54395-44-2-0 notary.Nicholas Papamichalaki* Avis est donné qui- Nicholas Papamichalakis.étudiant, domicilié et résidant de la cité de Wcstmount.district de Montréal, province de Québec, et résiliant au numéro civique 266 Lansdowne Avenue.Apt.14, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil |h>ur obtenir un décret changeant son nom en celui de Nicholas Michalis et le nom de sa fille en celui de Gail Mi-chahs.Montréal, le 24 septembre 1973.I*s procureurs du requérant.Tinkofk, Seal Siiaposnick 54396-44-2-0 & moscowitz.Nicholas Papamichalakis Notice is hereby given that Nicholas Papainichala-kis.Student, of the City of Wcstmount.District of Montreal, in the Province of Québec, and therein residing and domiciled at 266 Lansdownc Avenue.Apartment 14, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing his name to Nicholas Michalis and changing the name of his wife to (rail Michalis.Montreal.24th September.1973.TrXKOFT, Seal.Shaposnick & Moscowitz.54396-44-2-0 Attorneys for .I pplicanl.John Anthony Chapates.Avis est donné qu'une requête en chuiigcmt-iil de nom sera présentée au ministère de la Justice par Monsieur John Anthony Chapates.gérant, domicilié à 217 Avenue Stillview, app.SOS.Pointe-Claire.P.O.afin de changer son nom de famille de « Chapates i pour celui de « Chapatis -, le tout en conformité avec «la Loi du changement de nom \u2022 1965 S.Q.chapitre 77.Le notaire.54409-44-2-1) Clément I.am a uni:.John Anthom Chapato Notice is hereby given that Mr.John Anthony Chapates, manager residing at 217 Stillview, apt.SOS.Pointe-Claire, P.Q., will present an application to the Minister of Justice for the purpose of obtaining an order of the Lieutenant-(rnvi-rnor in Council changing his name from \"Chapates\" to \"Chapatis\".the whole in conformitv with the \"Change of Name Act\" 1965 S.Q.Chap.77.Clément Lamaiiiie.54409-44-2-1.Sotary.Marcel lloiilianiic Avis est par les présentes donné que Marcel llou-liannc.architecte, demeurant ii 635 est, rue Perreault.Rouyn, présentera au ministère de la Justice du Québec une requête pour ajouter le prénom de Hubert à ceux qu'il porte déjà.Le procureur du requérant, 54410-44-2-o Gustave Tasciiereav, notaire.Marcel Bouliannc Notice is hereby given that Marcel Boiiliaiine.architect, domiciled at 635 Perreault Street Fast.Rouyn, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec, to add the first name Hubert to those by which he is presently known.Gustave Taschekeau, notary.54410-44-2-o Attorney for applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n° U 6473 Rachid Maurice Mouawad Avis est donné que Rachid Maurice Mouawad, médecin, domicilié à 4580 chemin Queen Mary, apt.209, dans la cité et district de Montréal, s'adressera au ministre de la justice, aux fins de changer son nom à Rachid Maurice Mawad, et aussi pour faire bénéficier son épouse, Marie-Thérèse Rachid Azize Mouawad, et son fils mineur, Maurice Rachid Mouawad, de la même adresse.Montréal, le 24 octobre 1973.Les procureurs du requérant, 54397-44-2-0 Garbkr & Reinblatt.Rachid Maurice Mouawad Notice is given that Rachid Maurice Mouawad, physician, residing at 4580 Queen Mary Road, Apt.209, in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Justice to change his name to Rachid Maurice Mawad, and also to benefit his wife, Marie-Thérèse Rachid Azize Mouawad, and his minor son, Maurice Rachid Mouawad, of the same address.Montreal, October 24, 1973.Garber & Reinblatt, 54397-44-2-0 Attorneys for applicant.Compagnies étrangères Agent Extra-Provincial Companies Agent CAN-AM LIQUIDS CO., LTD.Avis est donné qu'en vertu d'une nouvelle procuration en date du 14 septembre 1973, dont copie a été remise au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, monsieur Claude Girard du 500, Grande-Allée est, suite 609, Québec, a été nommé en remplacement de monsieur Georges Dubé à titre d'agent principal dans la province de « CAN-AM LIQUIDS CO., LTD.», une compagnie étrangère dûment autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies étrangères.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 500, Grande-Allée est, suite 609, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Fernand Lalonde.54370 PA: 59-69 CAN-AM LIQUIDS CO., LTD.Notice is given that, by new power of attorney dated September 14th, 1973, a copy of which was sent to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, Mr.Claude Girard, of Suite 609, 500 Grande-Alice East, Québec, was appointed to replace Mr.Georges Dubé as chief agent in the Province of \"CAN-AM LIQUIDS CO.LTD.\", an Extra-Provincial Company duly authorized to carry on business in the Province of Québec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act.The principal office of the company in the Province is at Suite 609, 500 Grande-Allée East, Québec, judicial District of Québec.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54370-o PA: 59-69 Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses TERMINAL RENTAL INC.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « TERMINAL RENTAL INC.» a reçu l'autorisation d'exercer son commerce dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur Gaétan Lachance, Highway 9A, Lacolle.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à Highway 9A.Lacolle, district judiciaire d'Ibervillc.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies el coopératives, (par intérim) Albert Jessop.54295 PA: 57-73 TERMINAL RENTAL INC.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"TERMINAL RENTAL INC.\", has been authorised to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Gaétan Lachance, Route 9A, Lacolle.The principal office of the company in the Province is at Route 9A, Lacolle, judicial district of Iberville.Albert Jessop, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54295-0 PA: 57-73 6474 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U__ CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE DOMINION TEXTILE COMPANY LIMITED, DIVISION VALLEYFIELD (Loi des Caisses d'épargne el de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 16 juin 1973 par « LA CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE MONTREAL COTTONS LTD.¦* changeant son nom en celui de « CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE DOMINION TEXTILE COMPANY LIMITED, DIVISION VALLEYFIELD ».Québec, le 4 octobre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies el coopérai ires {par intérim).54363-0 Albert Jessop.CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE DOMINION TEXTILE COMPANY LIMITED, DIVISION VALLEYFIELD (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, has approved the bylaw adopted on -lune 16, 1973, by \"LA CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE MONTREAL COTTONS LTD.\" changing its name to that of \"CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE DOMINION TEXTILE COMPANY LIMITED.DIVISION VALLEYFIELD\".Québec, October 4, 1973.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 54363 Companies and Cooperatives.CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE L'IMPERIAL OIL LIMITED, MONTREAL IMPERIAL OIL LIMITED MONTREAL EMPLOYEES CREDIT UNION (Loi des Caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 30 mars 1973 par « IMPERIAL OIL REFINERY EMPLOYEES (MONTREAL EAST) CREDIT UNION » changeant son nom en celui de «CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE L'IMPERIAL OIL LIMITED.MONTREAL » en français et de « IMPERIAL OIL LIMITED MONTREAL EMPLOYEES CREDIT UNION » en anglais.Québec, le 4 octobre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies el coopératives (par intérim), 54364-0 Albert Jessop.CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE L'IMPERIAL OIL LIMITED, MONTREAL IMPERIAL OIL LIMITED MONTREAL EMPLOYEES CREDIT UNION (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, has approved the bvlaw adopted on March 30, 1973.bv \"IMPERIAL OIL REFINERY EMPLOYEES (MONTREAL EAST) CREDIT UNION\" changing its name to that of \"CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE L'IMPERIAL OIL LIMITED, MONTREAL\" in French, and \"IMPERIAL OIL LIMITED MONTREAL EMPLOYEES CREDIT UNION\" in English.Québec, October 4, 1973.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 54364 Companies and Cooperatives.LA CAISSE POPULAIRE DE ST-ALEXIS-DES-MONTS {Loi des Caisses d'épargne el de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 28 juin 1973 par « LA CAISSE POPULAIRE DE ST-ALEXIS-DES-MONTS» modifiant son territoire qui était « la Paroisse de Saint-Alexis » en celui de la « Paroisse Saint-Alexis, district electoral de Maskinongé, Paroisse Saint-Paulin, Village Saint-Paulin.Paroisse Sainte-Angèle, Canton Hunterstown, Saint-Edouard et Paroisse Saint-Élie >.Québec, le 4 octobre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 54365-0 Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DE ST-A LEX IS-DES-MONTS {Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on June 28, 1973, by \"LA CAISSE POPULAIRE DE ST-ALEXIS-DES-MONTS\" changing its territory, which was \"the Parish of St.Alexis\" to that of the \"Parish of St.Alexis, the Electoral District of Maskinongé, Parish of St.Paulin, Village of St.Paulin, Parish of Ste.Angèle, Township of Hunterstown.St.Edouard and Parish of St.Élie.\" Québec, October 4, 1973.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 54365 Companies and Cooperatives.Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n° U 6475 CAISSE POPULAIRE VILLE SAINT-PIERRE (Loi des Caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 30 mai 1973 par « LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PIERRE-AUX-LIENS » changeant son nom en celui de < CAISSE POPULAIRE VILLE SAINT-PIERRE ».Québec, le 4 octobre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 54366-0 Albeht Jessop.LA CAISSE DE PREVOYANCE NOTRE-DAME DE LEVIS (Loi des caisses d'épargne el de crédit) Avis est donné que « LA CAISSE DE PREVOYANCE NOTRE-DAME DE LEVIS » a été dissoute le 18 octobre 1973 et ce, en vertu île la Loi des caisses d'épargne et de crédit et de la Ix)i de la liquidation des compagnies.Québec, le 23 octobre 1973.Le sous-7ninislre des institutions financières, compagnies et coopératives, (par intérim), 54422-0 Albert Jessop.CAISSE POPULAIRE VILLE SAINT-PIERRE (Savings and Credit Unions Aci) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, has approved the bylaw adopted on May 30.1973, by \"LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PIERRE-AUX-LIENS\" changing its name to that of \"CAISSE POPULAIRE VILLE SAINT-PIERRE'.Québec, October 4.1973.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 54366 Companies and Cooperatives.LA CAISSE DE PREVOYANCE NOTRE-DAME DE LEVIS (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that \"LA CAISSE DE PREVOYANCE NOTRE-DAME DE LEVIS\" was dissolved on October 18, 1973 pursuant to the Savings and Credit Unions Act and the Winding-Up Act.Québec, October 23, 1973.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institulions.54422 Companies and Cooperatives.Associations coopératives Cooperative Associations LA CHAINE COOPERATIVE DU SAGUENAY, ASSOCIATION COOPERATIVE (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement spécial adopté le 10 septembre 1973.modifiant les fins de «LA CHAINE COOPERATIVE DU SAGUENAY.ASSOCIATION COOPERATIVE ».dont le siège social est situé à St-Bruno, dans le district électoral de Lac St-Jean.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies el coopératives (par intérim), 54367-0 Albert Jessop.LA CHAINE COOPERATIVE DU SAGUENAY, ASSOCIATION COOPERATIVE (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives has approved the special bylaw adopted on September 10.1973.modifying the objectives of \"LA CHAINE COOPERATIVE DU SAGUENAY, ASSOCIATION COOPERATIVE\" whose head office is located in St.Bruno, in the Electoral District of Lac St.Jean.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 54367 Companies and Cooperatives.Avis divers Miscellaneous Notices CENTRE SPORTIF CATHEDRALE Prenez avis que la Corporation « CENTRE SPOR-TD7 CATHEDRALE » ayant siège social à Saint-Jean, Diocèse de Saint-Jean et formé en vertu de l'article 20 de, la loi relative à la Constitution en Corporation des Évêques Catholiques Romains, 14 Georges VI, chapitre 76, est déclarée dissoute par la présente publication.t.Gérard-Marie Codehre, Ècéque de Saint-Jean-de-Québec.(Sceau) Le chancelier, 54399-o André Foisy.CENTRE SPORTIF CATHEDRALE Notice is given that the corporation \"CENTRE SPORTIF CATHEDRALE\", having its head office in St.Jean and constituted pursuant to Section 20 of the Act respecting the Incorporation of Roman Catholic Bishops, 14 Georges VI, Chapter 76, is dissolved by the present publication.(Seal) 54399 t Gérahd-Mahie Coderre, Bishop of St.Jeaii-de-Québec.André Foisy, Chancellor. 6476 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Municipalité de Village Francoeur Municipalité de la paroisse de St-Apollinaire Avis est par les présentes donné que le conseil de la municipalité de Village Francoeur et le conseil de la municipalité de la Paroisse de St-Apollinaire ont adopté, à la majorité de leurs membres, des règlements, soit le règlement no 114 de la municipalité de Village Francoeur et le règlement no 208 de la municipalité de la paroisse de St-Apollinaire, autorisant ces municipalités à présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil pour fusionner les municipalités de Village Francoeur et Paroisse St-Apollinaire et créer la nouvelle municipalité de St-Apollihaire aux conditions suivantes: a) Le nom de la nouvelle municipalité sera la « Municipalité de St-Apollinaire»; 6) Le territoire de la nouvelle municipalité sera celui déterminé par la description technique en date du 27 septembre 1973.préparée par M.Jacques Coulombe, arpenteur-geomètre.et annexée à la présente pour en faire partie comme si elle était ici au long reproduite; c) La nouvelle municipalité sera régie par le Code municipal; d) Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux (2) conseils existant au moment de la fusion.Le quorum sera de huit (8) membres.Les deux maires actuels alterneront comme maire du conseil provisoire pour deux (2) périodes égales qui couvriront le temps séparant la première assemblée et la date de la première élection générale.Le premier maire à exercer ce rôle sera déterminé lors de la première assemblée; e) La première assemblée du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à 20 heures dans la salle de l'Hôtel de ville de Francoeur et de St-Apollinaire; /) La première élection générale aura lieu le premier dimanche du mois suivant le trentième jour de l'entrée en vigueur des lettres patentes.Les élections subséquentes, tel que prévu par l'article 249c et d du ('ode municipal, auront lieu le premier dimanche de novembre de chaque année.La durée du mandat des membres du conseil sera de trois (3) ans.Les sièges seront numérotés de un (1) à six (6); g) Le secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité sera M.Laurent Lamontagnc, secrétaire-trésorier actuel des municipalités de Francoeur village et de St-Apollinairc: h) Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des municipalités requérantes deviendront la propriété de la nouvelle municipalité; i) Les règlements, procès-verbaux, rôles de perception et autres actes de chacune des municipalités requérantes demeureront en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés par la nouvelle municipalité; j) Les emprunts à long terme contractés par chacune des municipalités seront remboursés conformément aux clauses d'imposition de chacun des règlements; Municipality of Village Francoeur Municipality of the Parish of St.Apollinaire Notice is hereby given that the Council of the Municipality of Village Francoeur and the Council of the Municipality of the Parish of St.Apollinaire have adopted, at the majority of their members, bylaws, namely Bylaw No.114 for the Municipality of Village Francoeur and Bylaw No.208 for the Municipality of the Parish of St.Apollinaire, authorizing said municipalities to submit a petition to the Lieutenant-Governor in Council for the amalgamation of the municipalities of Village Francoeur and of the Parish of St.Apollinaire and the forming of the new Municipality of St.Apollinaire according to the following conditions: (a) The name of the new municipality shall be the \"Municipality of St.Apollinaire\"; (6) The territory of the new municipality shall be the one denned in the technical description dated September 27, 1973, prepared by Mr.Jacques Coulombe, land-surveyor, and attached to the present notice to form part thereof as if it were reproduced in full; (c) The new municipality shall be governed by the Municipal Code; (d) A Provisional Council shall be in office until the first general election.It shall be composed of all the members of the two councils cxistir^ at the time of the amalgamation.Quorum shall he oi eight (8) members.The two present mayors shall alternate as mayor of the Provisional Council for two equal periods covering the time between the first meeting and the date of the first general election.The first mayor to hold office shall be appointed at the first meeting; (*) The first meeting of the Provisional Council shall be held on the second legal Monday following the coming into force of the letters patent.It shall be held at 8:00 o'clock p.m., in the Municipal Hall of Francoeur and of St.Apollinaire; (/) The first general election shall be held on the first Sunday of the month following the thirtieth day of the coming into force of the letters patent.The subsequent elections, as provided by section 249c and d of the Municipal Code, shall be held on the first Sunday of November of each year.The term of office of the members of the Council shall be three (3) years.The seats shall be numbered from one (1) to six (6); (g) The Secretary-Treasurer of the new Municipality shall be Mr.Laurent Lamontagne, who is the present Secretary-Treasurer of the Municipalities of Francoeur and St.Apollinaire; (h) All the moveable and immoveable property belonging to each petitioning municipality shall become the property of the new Municipality; (i) The bylaws, resolutions, minutes, collection rolls and other instruments of each petitioning municipality shall remain in force in the territory for which they were made until amended, cancelled or repealed by the new Municipality; (j) The long-term loans contracted by each municipality shall be reimbursed in conformity with the taxation clauses stipulated in each bylaw; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n\" U 6477 k) Les surplus ou les déficits seront au bénéfice ou à la charge du secteur qui a accumulé le surplus ou occasionné le déficit; f) La nouvelle municipalité deviendra effective conformément à la loi; Tout propriétaire ou tout locataire des municipalités concernées peut s'opposer au principe de la fusion ou aux modalités de la requête conjointe dans les trente jours qui suivent la date de la dernière parution dans un journal du présent avis et peut faire connaître les motifs de son opposition en s'adressant par écrit à la Commission.On peut prendre connaissance et obtenir copie du texte de la requête conjointe aux secrétariats des municipalités de village Francoeur et paroisse St-Apollinaire.Le secrétaire-trésorier de la municipalité de tillage Francoeur, 54373-o Laurent Lamontagne.Ville de Montréal Règlement 4674 Constatation de l'annexion de certains lots situés en la municipalité' de Saint-Jean-de-I)ieu.A la séance du conseil de la ville de Montréal tenue le 18 octobre 1973, Vu les dispositions de l'article 57 du chapitre 70 des lois de 1963, loi modifiant la charte de la cité de Montréal, le conseil décrète: 1.Est constatée l'annexion à la Ville de Montréal, comme faisant partie du quartier Mercier et du district électoral Mercier, de certains lots qui ont fait l'objet de la vente, entre la Communauté des Soeurs de Charité de la Providence et Monsieur Jean-Claude Lalonde.passée devant Me Lambert Lamarche le 3 octobre 1973 et enregistrée sous le numéro 2,465,277 de la division d'enregistrement de Montréal; ces lots sont indiqués dans le plan ci-annexé portant le numéro A-1445, daté le 21 février 1973 par Monsieur René Beauparlant.arpenteur-géomètre, ledit plan étant identifié aux fins des présentes par le greffier de la Ville.Les lots vises et compris dans la partie du territoire de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu dont il est fait mention ci-dessus sont les suivants: Un terrain vague de forme irrégulière, ayant front sur le côté sud-est de la rue Sherbrooke et le côté sud de la Route Transcanadienne, en la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et le district de Montréal, et composé de : 1° Une partie de forme irrégulière du lot originaire trois cent trente-deux (ptie 332) du cadastre officiel de la paroisse île Longue-Pointe, laquelle partie est bornée en front vers le nord-ouest par la rue Sherbrooke qui fait partie du même lot 332, en arrière vers le sud-est et d'un côté vers le sud-ouest par d'autres parties dudit lot 332 et de l'autre coté vers le nord-est par la partie ci-après décrite du lot 335, et elle mesure vers le nord-ouest, suivant une ligne brisée, trente-cinq pieds (k) The accumulated surpluses or deficits shall remain the benefit or responsability of the sector who has accumulated the surplus or incurred the deficit; (/) The new Municipality shall become effective in conformity with the law; Any property-owner or tenant in the municipalities concerned may oppose the principle of amalgamation or the terms and conditions of the joint petition within the thirty days following the date of the final publication of the present notice in a newspaper, and may state the reasons for his objection in writing to the Commission.The text of the joint petition may be examined and a copy thereof is available at the Secretariates of the Municipalities of Village Francoeur and of the Parish of St.Apollinaire.Laurent Lamontagne, Secretary-Treasurer for the 54373 Municipality of Village Francoeur.City of Montreal By-law 4674 Recording of the annexation of certain lots situate in the Municipality of Saint-Jean-de-Dieu.At the meeting of the Council of the City of Montreal held on October 18.1973, Considering the provisions of Article 57 of Chapter 70 of the Acts of 1963, an Act to amend the Charter of the City of Montreal.Council ordained: (1) Record is made of the annexation to the City of Montreal, as part of Mercier Ward and of the electoral district of Mercier, of certain lots which were the subject of a sale between the Community of the Sisters of Charity of Providence and Mr.Jean-Claude Lalonde, executed before Mr.Lambert Lamarche on October 3, 1973 and registered under number 2,465,277 of the Montreal Registration Division; those lots arc shown on the attached plan bearing number A-1445 dated February 21, 1973 by Mr.René Beauparlant, Surveyor, the said plan being identified for these presents by the City Clerk.The lots under consideration, situate in the section of the territory of Saint-Jean-de-Dieu mentioned above are the following: A vacant lot, irregular in shape, fronting on the southeast side of Sherbrooke Street and the south side of the Trans-Canada Highway in the municipality of Saint-Jean-de-Dieu and the District of Montreal, made up of: (1) A part, irregular in shape, of original lot three hundred and thirty two (part 332) in the official cadastre of the Parish of Longue Pointe, which part is bounded on the front, towards the northwest, by Sherbrooke Street which is part of that same lot 332, at the rear, towards the southeast and on one side towards the southwest, by other parts of the said lot 332 and on the other side, towards the northeast by the section of lot 335 hereafter described, which measures towards 0478 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U et trois-dixièmes de pied (35.31).dix-sept pieds et soixante-sept centièmes de pieds (17.67') et quatre cent trente-cinq pieds et soixante-quinze centièmes de pied (435.75').vers le sud-ouest cinq cents pieds (500').vers le sud-est quatre cent quatre-vingt-trois pieds el soixante et un centièmes de pieds (483.610 et vers le nord-est cinq cent treize pieds et quatre-vingt-huit centièmes de pied (513.88').formant une superficie de deux cent quarante-sept mille six cent quarante-neuf pieds carrés (247.649 pi.ca.); 2° Une partie de forme irrégulière du lot originaire trois cent trente-cinq (ptie 335) du même cadastre, laquelle partie est bornée vers le nord-ouest le nord et encore le nord-ouest par la Route Transcanadienne faisant partie du même lot 335, vers le sud-ouest par la partie ci-dessus décrite du lot.332.vers le sud-est par une autre partie non .subdivisée dudit lot 335 et vers le nord-est par la partie ci-après décrite du lot 337.et elle mesure vers le nord-ouest cent sept pieds et soixante-quinze centièmes de pied (107.75').vers le nord cent quatre-vingt-douze pieds et huit centièmes de pied (192.08').vers le nord-ouest suivant une ligne brisée, soixante et onze pieds et quarante-cinq centièmes de pied (71.450.cent cinquante-cinq pieds et cinq-dixièmes de pied (155.50 et quatre-vingt-huit pieds et seize centièmes de pied (88.160.vers le sud-ouest cinq cent treize pieds et quatre-vingt-huit centièmes de pied (513.88').vers le «mi-est cinq cent huit pieds et soixante ec, ce 18e jour d'octobre, 1973.Le procureur de la compagnie, 4115 rue Sherbrooke ouest, Max Slapack, c.k.Montréal, Québec.54307-o YORK EQUIPMENT LIMITED Avis est donné que la compagnie « YORK EQUIPMENT LIMITED ».ayant son siège social à Candiac.province de Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province, la permission d'abandonner sa charte.Candiac, ce 16e jour d'octobre 1973.Le secrétaire, 54309-o Charles Wallace.LA COMPAGNIE SUR MER LIMITEE Conformément aux dispositions de la Loi des compagnies, « LA COMPAGNIE SUR MER LIMITEE » donne par les présentes avis de son intention de demander au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte, l'annulation de sa charte et la dissolution de la compagnie.Montréal, P.Q., ce 12e jour d'octobre 1973.Le secrétaire, 54402-o Percy Auger.ALCIDE ROUSSEAU INC.Prenez avis que la compagnie « ALCIDE ROUSSEAU INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 54403-o Me Lemire Frechette, notaire.AUTODROME GENTILLY INC.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « AUTODROME GENTILLY INC.», constituée en corporation suivant les dispositions de la Loi des compagnies, et ayant son siège social à Bécancour, dans le district de Nicolet, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour demander la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Trois-Rivières, ce 24 octobre 1973.Les procureurs de la compagnie, GlROUARD, BeAUMIER, 54404-o Richard & Roberge.SERVICE TOOL & DIE LTD.Notice is hereby given that \"SERVICE TOOL & DIE LTD.\", incorporated under the Companies Act and having its head office and principal place of business in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, Québec, this 18th day of October, 1973.Max Slapack, q.c, 4115 Sherbrooke St.West, Attorney for the company.Montreal, Québec.54307-o YORK EQUIPMENT LIMITED Notice is given that \"YORK EQUIPMENT LIMITED\" having its head office in Candiac, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province for leave to surrender its charter.Candiac, this 16th day of October, 1973.Charles Wallace, 54309-o Secretary.LA COMPAGNIE SUR MER LIMITEE Under the provisions of the Companies Act, \"LA COMPAGNIE SUR MER LIMITEE\" hereby gives notice that it intends to apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender the Charter of the Company, for cancellation of the Charter and for the dissolution of the Company.Montreal, P.Q., this 12th day October 1973.Percy Auger, 54402-o Secretary.ALCIDE ROUSSEAU INC.Notice is given that \"ALCIDE ROUSSEAU INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Me Lemire Frechette, Notary, 54403 Attorney for the Company.GENTILLY SPEEDWAY INC.Notice is hereby given that \"GENTILLY SPEEDWAY INC.», corporation incorporated under the Companies Act and having its head office at Bécancour, in the district of Nicolet, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter, under the provision of the Companies Act.Trois-Rivières, this October 24, 1973.GlROUARD, BEAUMIER, Richard & Roberge, 54404-O Attorneys for the Company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S novembre 1973, 105' année, n\" U 6483 Divers Compagnies Miscellaneous Companies CLINIQUE LA RENAISSANCE INC.La compagnie « CLINIQUE LA RENAISSANCE INC.» donne avis qu\"elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 4.Le secrétaire, René Amyot.54310-o 730357 CLINIQUE LA RENAISSANCE INC.Notice is given that \"CLINIQUE LA RENAISSANCE INC.\" has changed the number of its directors from 5 to 4.René Amyot, Secretary.54310 730357 LA CORPORATION FINANCIERE CANADIENNE CANADIAN FINANCIAL CORPORATION La compagnie « LA CORPORATION FINANCIERE CANADIENNE \u2014 CANADIAN FINANCIAL CORPORATION - donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 12 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, G.Whelan.54311 721358 LA CORPORATION FINANCIERE CANADIENNE CANADIAN FINANCIAL CORPORATION Notice is given that \"LA CORPORATION FINANCIERE CANADIENNE \u2014 CANADIAN FINANCIAL CORPORATION\" has changed the number of its directors from 3 to 12.G.Whelan, Secretary.54311-0 721358 DAWSON AUTO PARTS ST.GEORGES LTD.DAWSON AUTO PARTS ST.GEORGES LTD.La compagnie « DAWSON AUTO PARTS ST.GEORGES LTD.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Arthur Pascal.54312 5981-49 DESIGN FOCUS INC.La compagnie « DESIGN FOCUS INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire, Joseph Husson.54313-0 1161-68 MULTIGESCO INC.Règlement concernant la distribution aux actionnaires de tout l'actif de la compagnie Qu'il soit décrété et il est par les présentes décrété par les administrateurs de « MULTIGESCO INC.» comme règlement de ladite compagnie ainsi qu'il suit: Que la compagnie distribue parmi les actionnaires de la compagnie tout l'actif de la compagnie qui consiste au moment de la distribution uniquement d'argent au montant de $1,000, telle distribution devant être faite proportionnellement parmi les actionnaires suivant leurs droits et intérêts respectifs dans la compagnie; Que les administrateurs et officiers de la compagnie soient autorisés et dirigés par la présente à prendre les moyens nécessaires et à signer les documents requis pour l'accomplissement de ce qui précède.Le secrétaire-trésorier, 54400-o Bernard Painchaud.Notice is given that \"DAWSON AUTO PARTS ST.GEORGES LTD.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Arthur Pascal, Secretary.54312-0 5981-49 DESIGN FOCUS INC.Notice is given that \"DESIGN FOCUS INC.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.54313 Joseph Husson, Secretary.1161-68 MULTIGESCO INC.Bylaw respecting the distribution to the shareholders of all the assets of the Company That it be ordered and it is hereby ordered by the directors of -MULTIGESCO INC.\" as a bylaw of said Company reading as follows: That the company distribute among the share holders of the Company all the assets of the Company which consist, at the time of the distribution, solely in money in the amount of $1,000, such distribution shall be made on a pro rata basis among the shareholders according to their respective rights and interests in the Company ; That the directors and officers of the Company be authorized and governed by these presents to take the necessary steps and to sign the required documents for the execution of the foregoing.Bernard Painchaud, 54400 Secretary-Treasu rer. 6484 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.November 3, 1973.Vol.105, No.U LES ENTREPRISES JEAN-FAUR INC.La compagnie « LES ENTREPRISES JEAN-FAUR INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, René Amvot.54314-0 5713-65 KOKO INC.La compagnie « KOKO INC.¦\u2022 donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire-trésorier.Kiinie Hockenstein.54315 4912-67 MESSABEC LIMITEE La compagnie « MESSABEC LIMITEE donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 7.Le secrétaire.Normand Zadra.54316-0 15258-61 LES ENTREPRISES JEAN-FAUR INC.Notice is given that \"LES ENTREPRISES JEAN-FAUR INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Rene Amyot, Secretary.54314 5713-65 KOKO INC.Notice is given that \"KOKO IN< '.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Ernie Hockenstein, Secretary- Treasurer.54315-0 4912-67 MESSABEC LIMITEE Notice is given that \"MESSABEC LIMITEE\" has increased the number of its directors from 4 to 7.Normand Zadha.Secrrtor^.54316 15258-61 QUEBEC AVIATION AIR SERVICE INC.La compagnie « QUEBEC AVIATION AIR SERVICE INC.» donne avis qu'elle a change le nombre de ses administrateurs de 4 à 6.Le secrétaire.Pierre Lari i:.54318-0 1298-69 TEMBOIS INC.La compagnie «TEMBOIS INC.donne avis u'elle a changé le nombre île ses administrateurs e 3 à 5.Le secrétaire, J.Mason.54319-0 73297(1 QUEBEC AVIATION AIR SERVICE INC.Notice is given that \"QUEBEC AVIATION AIR SERVICE INC.\" has changed the number of its directors from 4 to 6.Pierre Larue.Secrctari/.5431S 1298-69 TEMBOIS INC.Notice is given that \"TEMBOIS INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 5.J.Mason, Secretary.54319 732979 a INTERN VTIONAL ROMAN HEALTH SPA LTD.SOURCE DE SANTE ROMAINE INTERNATIONALE LTEE .Ici* île con local ion à une assemblée en rerlu tin paragraphe SI delà Loi des compagnies Avis est donné par les présentes que les personnes désignées comme administrateurs dans les lettres patentes de « INTERNATIONAL ROMAN HEALTH SPA LTD - SOURCE DE SANTE ROMAINE INTERNATIONALE LIEE .en date du 5 juin 1973.sont convoquées à une assemblée qui aura lieu au numéro 720.boulevard Décarie.Ville St-Laurent.Québec, le 20e jour de novembre 1973, à 12.30 heures de l'après-midi aux fins de passer des règlements, faire la répartition d'actions et d'élire des administrateurs.Fait à Montréal, le 10e jour d'octobre 1973.[dminislraleur procisoire, René A.Dubé.I (/m in istrâleur provisoire.54424 Michel Fohcili.o.INTERNATIONAL ROMAN HEALTH SPA LTD.SOURCE DE SANTE ROMAINE INTERNATIONALE LTEE Notice of meeting under section 81 of the Companies Act Notice is hereby given that a meeting of the persons named as directors in the letters patent of \"INTERNATIONAL ROMAN HEALTH SPA LTD \u2014 SOURCE DE SANTE ROMAINE INTERNATIONALE LTEE\" dated June 5th.1973, is called, to be held at 720 boulevard Décarie, Ville St-Laurent, Québec, on the 20th day of November 1973, at 12.30 o'clock in the afternoon for the purpose of passing by-laws, allotting stock and electing directors.Dated at Montreal, the 10th day of October, 1973.René A.Dubé, Provisional director.Michel Forcillo, 54424-0 Provisional director. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1973, 105' année, n° U 6485 TK.MBKC FOREST PRODUCTS INC.PRODUITS FORESTIERS TEMBEC INC.La compagnie « TK.MBEC FOREST PRODUCTS INC.\u2014 PRODUITS FORESTIERS TEMBEC INC.» ilonne avis qu'elle a augmente de 3 à 9 le nom-lire de ses administrateurs./.c secrétaire, Skhgk Deshocheks.54317 723853 TEMBEC FOREST PRODUCTS INC.PRODUITS FORESTIERS TEMBEC INC.Notice is given that \"TEMBEC FOREST PRODUCTS INC.\u2014 PRODUITS FORESTIERS TEMBEC INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 9.Skhgk Deskochkhs.iSecrelari/.14317-.723853 Sièges sociaux Head Offices LES SPORTS A.L.I.INC.A.L.I.SPORTS INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie \u2022LES SPORTS A.L.I.INC.\u2014 A.L.I.SPORTS INC.».constituée en corporation par lettres patentes émises en date du 6 septembre 1973, en vertu de la première partie de la Loi des compagnies a établi son siège au 2351 Des Carrières.Montréal, district de Montréal.A compter île la date des présentes, ledit bureau sera considéré par la compganie comme étant son siège social et sa principale place d'affaires.Donné à Montréal, ce (i septembre 1973.(Sceau) Le secrétaire-trésorier.réjean r.LkkIIAXÇOIS.54320-0 738077 LES SPORTS A.L.I.INC.A.L.I.SPORTS INC.Notice is hereby given that \"LF:S SPORTS A.L.I.INC.\u2014 A.L.I.SPORTS INC.*'.a company incorporated by letters patent issued on September 6.1973 under the provisions of Part I of the Companies Act.has established its head office on 2351 Des Carrières, Montreal, district of Montreal.From and after the date of present notice, the said office shall be considered by the company as being the head office and principal place of business of said company.Dated at Montreal, this September 6,1973.(Seal) Réjean H.Lkfhançois, ¦Secretary-Treasurer.54320-o 738077 LES INGENIEURS ASSOCIES LIMITEE ASSOCIATED ENGINEERS LIMITED Avis est donné que la compagnie ¦ LES INGE-MEURS ASSOCIES LIMITEE \u2014 ASSOCIATED ENGINEERS LIMITED ».constituée en corporation par lettres patentes en date du 2 mai 1928 et ayant son bureau principal à Montréal, district de Montréal a établi son bureau au numéro 3300.boul.Cavendish No 385.Montréal 261.Que.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 13c jour de juillet 1973.Le président.Andiié Labhecqik.5432 l-o 579-28 BRASSERIE PLACE SAUVE INC.La compagnie « BRASSERIE PLACE SAUNÉ INC.» donne avis qu'elle a transféré son siège social du numéro 1380.boulevard O'Brien.Saint-Lambert, au numéro 350, boulevard Sauvé, Saint-Eustachc.Le secrétaire.Chkisto Lazahis.54322 737620 LES INGENIEURS ASSOCIES LIMITEE ASSOCIATED ENGINEERS LIMITED Notice is given that \"LES INGENIEURS ASSOCIES LIMITEE \u2014 ASSOCIATED ENGINEERS LIMITED\", incorportaed by letters patent dated May 2.1928, and having its head office in Montreal.District of Montreal, has established its office at 3300 Cavendish Boulevard, No.3S5.Montreal 201.Quebec.From the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as its head office.(siren in Montreal, this 13th day of July.1973.Aniuik Labrecqie./'resident.54321 579-2S BRASSERIE PLACE SAUVE INC.Notice is given that \"BRASSERIE PLACE SAUNÉ INC.\" has transferred its head office from 1380 O'Brien Boulevard, Saint-Lambert, to 350 Sauvé Boulevard.Saint-Eustachc.Chkisto Lazakis, Secretary.54322-0 737620 QUÉBEC OFF ICI.IL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U CENTRE DE CULTURE DIALOGUE ORIENTAL LIMITEE Avis est par les présentes donné que l'association: « CENTRE DE CULTURE DIALOGUE ORIENTAL LIMITEE % constituée en corporation dans la province de Québec, en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes portant la date du 9 juillet 1973, et ayant son siège social en la ville de Montréal, a établi son bureau principal au 5553 Chemin de la Reine-Marie, app.ti, à Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la cor|x>ration comme étant son siège social.Montréal, ce deux octobre 1973.(Sceau) l.e président, 54328-0 Ei.ik Bâcha.CENTRE DE CULTURE DIALOGUE ORIENTAL LIMITEE Notice il hereby given that the Association \"CENTRE DE CULTURE DIALOGUE ORIENTAL LIMITEE\", incorporated in the Province of Québec, under Part III of the Companies Act.by letters patent bearing the date of July the 9th.1973, and having its head office in the City of Montreal, has established its office at 55.Ï3 Queen Mary Road, apt.(i.Montreal.From and after the dale of this notice, the said office shall be considered by the Association as being its head office.Montreal, this second day of October 1973.(Seal) EUE Bacha.04323-e.President.D.K.M.DESIGNER'S KITCHEN MART INC.CENTRE D'ACCESSOIRES DE CUISINE POUR DECORATEURS D.K.M.INC.Avis est donné que la compagnie « D.K.M.DESIGNER'S KITCHEN MART INC \u2014CENTRE D'ACCESSOIRES DE CUISINE POUR DECORATEURS D.K.M.INC.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 28e jour de juin 1973.et ayant son siège social en la cité de Westmounl.dans le district de Montréal, a établi son bureau au numéro 4192 ouest, rue St-C'atlierine.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Le secretaire.54324-0 Dot Mi am Mitchell.D.K.M.DESIGNER'S KITCHEN MART INC.CENTRE D'ACCESSOIRES DE CUISINE POUR DECORATEURS D.K.M.INC.Notice is hereby given that \"D.K.M.DESIGNER'S KITCHEN MART INC.\u2014 CENTRE D'ACCESSOIRES DE CUISINE POUR DECORATEURS D.K.M.INC.\", incorporated under Part I of the Québec Companies Act by letters patent datcil the 28th day of June, 1973.and having its head office in the City of Westmount.District of Montreal, has established its office at number 4192 Ste.Catherine Street West.F'rom and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the Company.The Secretary.ô4324-o DouOLAB Mitchell.LES CONSTRUCTIONS MONTBERT INC.MONTBERT CONSTRUCTIONS INC.La compagnie « LES CONSTRUCTIONS MONTBERT INC.\u2014 MONTBERT CONSTRUCTIONS INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 135, 47e Rue est.Charlesbourg.au numéro 89, rue Pinson, N'eufchâtel./.a secrétaire.ClIANTAI.E RoY-MoNTREUIU 54326-0 725141 CORPORATION ENTEX Avis est par les présentes donné que la compagnie « CORPORATION ENTEX constituée en corporation dans la province de Québec, par lettres patentes en date du 30 août, 1973 et ayant son siège social à Beloeil, district judiciaire de Montréal, a établi son bureau principal au numéro 581, rue Vauquclin.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 16e jour d'octobre 1973.Le président, 54327-o Yves Newman.LES CONSTRUCTIONS MONTBERT INC.MONTBERT CONSTRUCTIONS INC.Notice is given that \"LES CONSTRUCTIONS MONTBERT INC.\u2014 MONTBERT CONSTRUCTIONS INC.\" has transferred its head office from 135-47th Street East, Charlesbourg, to 89 Pinson Street, N'eufchâtel.Chantale Roy-Montreuil, Secretary.54326 725141 CORPORATION ENTEX Notice is hereby given that \"CORPORATION ENTEX\", incorporated by letters patent dated August 30, 1973 issued pursuant to the provisions of Part I of the Companies Act of the Province of Québec, and having its head office in the Town of Beloeil, has established its office at 581 rue Vauquelin.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the Company.Dated at Montreal\", this 16th day of October 1973.Yves Newman, 54327 President. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n' U 6487 CENTRE D'ECHANGE CULTUREL EST-OUEST INC.EAST-WEST CULTURAL EXCHANGE CENTER INC.Avis est par les présentes donné que la corporation : « CENTRE D'ECHANGE CULTUREL EST-OUEST INC.- EAST-WEST CULTURAL EXCHANGE CENTER INC.», constituée en corporation dans la province de Québec, en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes portant la date du 31 août 1973 et ayant son siège social en la ville de Montréal, a établi son bureau principal au 3450, nie Dmmmond, Montréal H3G 1VI, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la corporation comme étant son siège social.Montréal, ce 19e jour d'octobre 1973.(Sceau) La présidente, 54325-0 Mlle Fumiko Mohikami.LA CORPORATION DE RECHERCHE S.P.A.La compagnie « LA CORPORATION DE RECHERCHE S.P.A.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 630 ouest boulevard Dorchester au numéro 980 ouest rue Ste-Catherine dans les cité et district de Montréal.Le secrétaire, G.M.Standish.54328-0 731034 DESIGN WORKSHOP LTD.Avis est donné que la compagnie « DESIGN WORKSHOP LTD.», constituée en vertu de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 1er mai.1967.et ayant son siège social et sa principale place d'affaires dans la ville d'Outrcmont province de Québec, l'a transporté au 234 Querbes.dans la ville d'Outrcmont.province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 30e jour d'août.1973.La secrétaire.54330-o .Taxina Maxcixi.CENTRE D'ECHANGE CULTUREL EST-OUEST INC.EAST-WEST CULTURAL EXCHANGE CENTER INC.Notice is hereby given that the corporation ^'CENTRE D'ÉCHANGE CULTUREL EST-OUEST INC.\u2014 EAST-WEST CULTURAL EXCHANGE CENTER INC.\", incorporated in the Province of Québec, under Part III of the Companies Act, by letters patent l>eariiig the date of August 31, 1973, and having its head office in the City of Montreal, has established its head office at 3450, Drummond Street, Montreal H3G 1V1, Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the corporation as being its head office.Montreal, this 19th day of October.1973.(Seal) Miss Fimiko Mokikami, 54325-0 President.S.P.A.RESEARCH CORPORATION Notice is given that \"S.P.A.RESEARCH CORPORATION\" has transferred its head office from 630 Dorchester Boulevard West to 980 St.Catherine Street West in the City and District of Montreal.G.M.Standish, Secretary.54328-0 731034 DESIGN WORKSHOP LTD.Notice is hereby given that \"DESIGN WORKSHOP LTD\", incorporated under the Companies Act by letters patent dated May 1.1967.and having its head office and principal place of business in the City of Outremont, Province of Québec, has moved it to 234 Querbes.in the City of Outremont.Province of Québec.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal', this 30th day of August 1973.Iaxixa Mancini, 54330-o Secretary.LES ENTREPRISES CAROL COULOMBE LTEE Avis est donné que « LES ENTREPRISES CAROL COULOMBE LTEE , constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, en date du vingt juillet mil neuf cent soixante-treize et ayant son siège au 1295, avenue Loti, Québec 8, P.Q.a établi son bureau à ladite adresse.A compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Québec, ce 10e jour d'octobre 1973.Le secrétaire-trésorier, 54333-o Roch Paquet.LES ENTREPRISES CAROL COULOMBE LTEE Notice is given that \"LES ENTREPRISES CAROL COULOMBE LTEE\".incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patent issued on July twenty one thousand nine hundred seventy-three, and having its head office at 1295 Loti Avenue.Québec 8, P.Q., has established its office at said address.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as its head office.Given at Québec, this 10th day of October 1973.Roch Paquet, 54333 Secretary-Treasurer. 648S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, .Xocember 3, 1973, Vol.105.No.U DAWSON AUTO PARTS ST.GEORGES LTD.La compagnie « DAWSON AUTO PARTS ST.GEORGES LTD.» donne avis qu'elle a transféré son siège social de Saint-Georges, Beauce, au numéro 901, rue Bleury, Montréal.Le secrétaire.Aktiur Pascal.54329 5981-49 DAWSON AUTO PARTS ST.GEORGES LTD.Notice is given that \"DAWSON AUTO PARTS ST.GEORGES LTD.\" has transferred its head office from Saint-Georges.Beauce.to 901 Bleury Street, Montreal.Aktiur Pascal, Secretary.54320-o 5981-49 DRUMMOND WELDING AND STEEL WORKS LTD.Avis est donné que la compagnie \u2022 DRUMMOND WELDING AND STEEL WORKS LTD.», constituée en corporation par lettres patentes du 17 mars 1970 et ayant son siège social dans Longueuil où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 2277 de la rue Joliette.l'a transporté au numéro 700 de la rue Talon.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 10 août 1973.Le secrétaire.54331-0 Serge Desrocheks.DRUMMOND WELDING AND STEEL WORKS LTD.Notice is hereby given that the Head Office of \"DRUMMOND WELDING AND STEEL WORKS LTD.\" has been changed, effective July 30th.1973 from 2277.Joliette street.Longueuil, in the Province of Québec, to 700 Talon street.Longueuil.in the Province of Québec, by By-law No.36.sanctioned and confirmed by the shareholders of the Company on August 10th.\" 1973.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal.August 10th.1973.Serge Deshochers.54331 -o Secretary.LES EDITIONS FLECHE INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « LES EDITIONS FLECHE INC.-, constituée en corporation par lettres patentes émises en date du 19 juillet 1973, en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, a établi son siège social au 7901.Wilfrid-Peljetier, Ville d'Anjou, district de Montréal.A compter de la date des présentes, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social et sa principale place d'affaires.Donné à Ville d'Anjou, ce 1er août 1973.(Sceau) Le président, Jkax-Maikice Laxglois.54332-0 737666 LES EDITIONS FLECHE INC.Notice is hereby given that \"LES EDITIONS FLECHE INC.a company incorporated by letters patent issued on July 19th.1973 under the provisions of Purt I of the Companies Act, has established its head office at 7901 Wilfrid-Pelletier.Ville d'Anjou, district of Montreal.From and after the date of present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office and principal place of business of said company.Dated at Ville d'Anjou, this August 1st, 1973.(Seal) .Ikan-Macricf.Laxglois, President.54382-0 737666 FREDETTE & MALOUIN TIRE SERVICE INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « FREDETTE & .MALOUIN TIRE SERVICE INC.% constituée en corporation dans la province de Québec, en vertu delà première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes portant la date du 5 décembre 1972 et ayant son siège social en la Cité de St-lx-onard.a établi son bureau principal au 4620 rue Viterbc.Cité de St-Léonard.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Montréal,ce leroctobre 1973.(Sceau) Le président, \u202254336-0 Frank Malolin.FREDETTE & MALOUIN TIRE SERVICE INC.Notice is hereby given that the Companv \"FRK-DETTE & MALOUIN TIRE SERVICE INC.\".incorporated in the Province of Québec, under Part I of the ('ompanies Act.by letters patent bearing the date of December 5th.1972 and having its head office in the City of St.I^onard has established its office at 4620 Vitcrhc Street, St.Ix-onard.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being its head office.Montreal, this October 1st, 1973.(Seal) Frank Malouin, 54336-0 President. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1973, 105' année, n° U 6489 LES ENTREPRISES EMLUC LTEE Avis est donné que la compagnie « LES ENTREPRISES EMLUC LTEE », constituée par lettres patentes datées du 7 juillet 1972 et ayant son siège social à Montréal, P.Q., a établi son bureau principal au 8401 est.boulevard Métropolitain. compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, P.Q., ce 5e jour d'octobre 1973.54334-0 Le président, Luc Lehoux.723827 J.G.FISET INC.Avis vous est donné que la compagnie J.G.FISET INC.\", constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, en date du 16 mai 1973 et ayant son bureau principal à Pont-Rouge, comté de Portneuf, a établi son bureau à Grand-Remous (CP.151) Pont-Rouge, comté de Portneuf.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Donnacona, ce 19 septembre 1973.Le president, 54335-0 Jean-Guy Fiskt.GRA-CEL LTEE \u2014 GRA-CEL LTD.La compagnie «GRA-CEL LTEE \u2014 GRA-CEL LTD.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 840, rue St-Vallier ouest, Québec, au numéro 2333, rue Galvani, Sainte-Foy.Le secrétaire, Mme Gracia JubIN ville.54337-0 5202-67 MEKA AUTOMOBILES INC.Avis est donné que la compagnie « MEKA AUTOMOBILES INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 avril 1972 et ayant son siège social dans la ville de Québec a établi son bureau au 332 St-Sacrement.A compter de la date «lu présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Québec, ce 9 octobre 1973.Le secrétaire, 54341-0 Gilles Ethieh.LES ENTREPRISES EMLUC LTEE Notice is hereby given that \"LES ENTREPRISES EMLUC LTEE\", incorporated by letters patentdated July 7, 1972, and having its head office in Montreal, P.Q, has established its head office at 8401 Metropolitan Blvd.East.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the Company as being its head office.Given at Montreal, P.Q., this 5th dav of October, 1973.Luc Lehoux, President.54334-0 723827 J.G.FISET INC.Notice is hereby given that \"J.G.FISET INC.\", incorporated by letters patent bearing date the 16th day of May 1973, and having its head office in the city of Pont-Rouge, county of Portneuf, has established its office at Grand-Remous (CP.151) Pont-Rouge, county of Portneuf.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Donnacona, this 19th September, 1973.Jean-Guy Fiset, 54335-0 President.GRA-CEL LTEE \u2014 GRA-CEL LTD.Notice is given \"GRA-CEL LTEE \u2014 GRA-CEL LTD\" has transferred its head office from 840 St.Vallier Street West, Québec to 2333 Galvani Street, Ste.Foy.Mrs.Gracia Jubinville, Secretary.54337 5202-67 .MEKA AUTOMOBILES INC.Notice is given that \"MEKA AUTOMOBILES INC\", incorporated by letters patent dated April 24, 1972, and having its head office in the City of Québec, has established its office at 332 St.Sacrement.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as its sead office.Given at Quebec, this 9th of October, 1973.Gilles Éthier, 54341 Secretary.PASCAL-DAWSON LIMITED La compagnie « PASCAL-DAWSON LIMITED » donne avis qu'elle a transféré son siège social de Sherbrooke au numéro 901, rue Bleury, Montréal.Le secrétaire, Arthur Pascal.54342 1704-33 PASCAL-DAWSON LIMITED Notice is given that \"PASCAL-DAWSON LIMITED\" has transferred its head office from Sherbrooke, to 901 Bleury Street, Montreal.Arthur Pascal, Secretary.54342-0 1704-33 6490 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1973, Vol.105, No.U INDUSTRIES DRUMMOND LTEE Avis est donné que la compagnie « INDUSTRIES DRUMMOND LTEE », constituée en corporation par lettres patentes du 14 février 1963 et ayant son siège social dans Longueuil où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 2277 de la rue Joliette, l'a transporté au numéro 700 de la rue Talon.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 10 août 1973.Le secrétaire.Serge Dkskochbbs.54338-o 674-63 INTERNATIONAL ACCEPTANCE CORPORATION La compagnie «INTERNATIONAL ACCEPTANCE CORPORATION donne avis quelle a transféré son siège social de Montréal à Lasalle.Le secrétaire.Pierre Hogik.54339 15676-59 INDUSTRIES DRUMMOND LTEE Notice is hereby given that the head office of \"INDUSTRIES DRUMMOND LTEE\" has been changed, effective July 30th.1973 from 2277, Joliette street, Longueuil, in the Province of Québec, to 700 Talon street, Longueuil, in the Province of Québec, by By-law No.76, sanctioned and confirmed by the shareholders of the company on August 10th, 1973.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal.August 10th, 1973.Serge Deshochers, Secretary.54338-0 674-63 INTERNATIONAL ACCEPTANCE CORPORATION Notice is given that \"INTERN ATIONAL ACCEPTANCE CORPORATION\" has transferred its head office from Montreal to Lasallc.Pierre Hogue, Secretary.54339-0 15676-59 LES JARDINS PRINCE ARTHUR INC.Avis est par les présentes lionne que la compagnie «LES JARDINS PRINCE ARTHUR INC.», constituée en corporation dans la province de Québec, par lettres patentes en date du 4 décembre 1973 et ayant son siège social à Montréal, district judiciaire de Montréal, a établi son bureau principal au numéro 1350.rue Sherbrooke ouest.Suite 1040.Montréal.Québec.À compter de la date du present avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 18c jour d'octobre 1973.Le président.54340-o Maurice Dksnoyeus.LES JARDINS PRINCE ARTHUR INC.Notice is hereby given that \"LES JARDINS PRINCE ARTHUR INC.\", incorporated by letters patent dated December 4.1973 issueil pursuant to the provisions of Part I of the Companies Act of the Province of Québec and having its head office in the District of Montreal, has established its office at 1350 Sherbrooke Street West.Suite 1040.Montreal.Québec.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 18th day of October, 1973.Maurice Desnoyers, 54340-o President.DE PASSILLE-SYLVESTRE INC.Avis est ilonné.par les présentes, que la compagnie « DE PASSILLE-SYLVESTRE INC.constituée en corporation en vertu de la premiere parti, de la Loi des corporation en vertu de la première paftie de la Loi des 25 mai 1973 et ayant son siège social en la ville de Ste-Adèle, district de Terrebonne, a établi son bureau principal à Chemin de la Laurentie.Stc-Adèlc, province de Québec. compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Ste-Adèle, ce 29c jour de septembre 1973.Le secrétaire, Micheline de Passille-Sylvestre.54343-0 732417 DE PASSILLE-SYLVESTRE INC.Notice is hereby given that the company \"DE PASSILLE-SYLVESTRE INC.\", incorporated under the provisions of Part I of the Companies Act (Québec) by letters patent dated May 25.1973 and having its head office in the City of Ste-Adèle.district of Terrebonne, has established its office at Chemin de la Laurentie, Ste-Adèle.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Ste-Adèle.this 29th day of September 1973.Micheline de Passille-Sylvestre, Secretary.54343-0 732417 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.3 novembre 1973, 105' année, n' U 6491 PELLETIER & MARTIN LTEE La compagnie « PELLETIER & MARTIN LTÉE » donne avis qu'elle a changé son siège social de La Pocatière à Saint-Louis-du-Ha !-Ha ! Le secrétaire.Simon Cakon.54344-0 10475-54 PIPOBEK INTERNATIONAL INC.Avis est donné que la compagnie « PIPOBEK INTERNATIONAL INC.» constituée en corporation par lettres patentes émises en date du vingt-huitième jour de juin 1972.et ayant son siège social à Mont Si-Grégoire, a établi son bureau au 320 avenue de la Montagne, district d'Iberville.À compter de la date du présent avis ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Mont St-Grégoirc.ce 26c jour de septembre 1973.La secrétaire.54345-0 Hélène Guibohd.PELLETIER & MARTIN LTEE Notice is given that \"PELLETIER & MARTIN LTÉE\" has transferred its head office from La Pocatière to St.Louis-du-Ha !-Ha ! Simon Caron.Secretary.54344 10475-54 PIPOBEK INTERNATIONAL INC.Notice is given that \"PIPOBEK INTERNATIONAL INC.\".incorporated by letters patent issued on the twenty-eighth day of June.1972.and having its head office in Mont St-Giégoire has established its office at number 320.Avenue de la Montagne, district of Iberville.From and after the dale of the present notice, the said office is considered by the company as licing the head office of the company.Given at Mont St-Grégoire.this 20th dav of September, 1973.HÉLÈNE GlIBORD, 54345-0 Secretary.PLACE ST-MARTIN INC.Avis est donné par les présentes que la compagnie PLACE ST-MARTIN INC.constituée en corporation par lettres patentes en date du 1er août 1973 a son siège social au 115.boul.des Laurentides.Pont-Viau, Ville de Laval, dans le district de Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Laval, ce quatrième jour de septembre mil neuf cent soixante-treize (1973).(Sceau) Le président, 54346-0 Real Bernier.PLACE ST-MARTIN INC.Notice is hereby given that \"PLACE ST-MARTIN INC.\".incorporated by letters patent dated August 1, 1973, has its head office at 115 Des Laurentides Boulevard.Pont-Viau, City of Laval, in the District of Montreal.From the date of this notice the said office shall be considered by the Company as its head office.Given in Laval, this fourth day of September one thousand nine hundred seventy-three (1973).(Seal) Real Bernier, 54346 President.PRODUCTIONS NIKKI INC.La compagnie « PRODUCTIONS NIKKI INC.> donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 500.rue St-François.appartement 506.tlc-aiix-Soeurs.Verdun, à Adamsville.La secrétaire.Nicole Hicken.54347-0 3782-71 PRODUCTIONS NIKKI INC.Notice is given that \"PRODUCTIONS NIKKI INC.\" has transferred its head office from 500 St.Francois Street Apartment 506.île-aux-Soeurs, Verdun, to Adamsville.Nicole Hicken, Secretary.54347 3782-71 QUEBEC EXPANSION LIMITEE QUEBEC EXPANSION LIMITED Prenez avis que la compagnie « QUEBEC EXPANSION LIMITEE \u2014 QUEBEC EXPANSION LIMITED », s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 19 octobre 1973.Me André Gauthier, 54348-0 Avocat.QUEBEC EXPANSION LIMITEE QUEBEC EXPANSION LIMITED Take notice that \"QUEBEC EXPANSION LIMITEE \u2014 QUEBEC EXPANSION LIMITED\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and cooperatives, for leave to surrender its charter.Montreal, October 19th, 1973.Me André Gauthier, 54348-0 Lawyer. 6492 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U LES REMORQUES HILL INC.HILL TRAILERS INC.Avis est donné que la compagnie « LES REMORQUES HILL INC.\u2014 HILL TRAILERS INC.».constituée en corporation en date du 3 octobre 1973 et ayant son siège social dans le district de Montréal, a établi son bureau au 6276 boul.Galeries d'Anjou, Vilje d'Anjou.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 17 octobre 1973.(Sceau) Le président.54349-0 Fernand Gadoury.LES REMORQUES HILL INC.HILL TRAILERS INC.Notice is given that \"LES REMORQUES HILL INC.\u2014 HILL TRAILERS INC\", incorporated on October 3th.1973, and having its head office in the district of Montreal, has established its office at 6276 boul.Galeries d'Anjou, Ville d'Anjou.From and after the date of this notice, the said office will be considered by the company as its head office.Given at Montreal, this 17th day of October 1973.(Seal) Fehnand Gadoury, 54349-0 President.MAURIL SIROIS LIMITEE Avis vous est donné que la compagnie « MAURIL SIROIS LIMITEE », constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu des dispositions de ta première partie de la loi des compagnies, en date du 31 décembre 1971, et ayant son bureau principal en la cité de Châteauguay Centre, a établi son bureau au no.75 boulevard St-.!ean-Baptiste, suite 201.Ville de Châteauguay.Que.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Châteauguav, ce 1er jour de septembre 1973.Le président, 54350-o Mauril Sirois.MAURIL SIROIS LIMITEE Notice is herebv given that the company \"MAURIL SIROIS LIMITÉE\", incorporated by letters patent bearing date the 31st of December 1971.and having its head office in the city of Châteauguay Centre, county of Châteauguay, has established its office in the city of Châteauguay, at number 75 St-Jean-Baptiste Boulevard, suite 201.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered !,y lue company as being its head office.Given at Châteauguay.this 1st day of September 1973.M.vuhil Sirois.54350-o President.SOCIETE D'INVESTISSEMENT POCAMAR INC.Avis est donné que la compagnie « SOCIETE D'INVESTISSEMENT POCAMAR INC », constituée en corporation par lettres patentes de la province de Québec, en date du 4e jour d'avril 1973.et ayant son siège social dans la ville de Sore!, a établi son bureau principal au no.4 de la rue Champoux.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Sorel, Que., ce 4e jour d'octobre 1973.(Sceau) Le président, 54351-0 Guy Germain.SOCIETE D'INVESTISSEMENT POCAMAR INC Notice is given that \"SOCIETE D'INVESTISSEMENT POCAMAR INC\", incorporated by letters patent of the Province of Quebec dated the 4th day of April.1973.and having its head office in the City of Sorel.has established its principal office at No.4 of Champoux Street.From the date of the present notice, said office .shall be considered by the Company as its head office.Given in Sorel, Québec, this 4th day of October, 1973.(Seal) Guy Germain, 54351 President.LE THEATRE DU TRIDENT Avis est donné que » LE THEATRE DU TRIDENT », incorporé en date du 17 mars 1970 (enregistré le 12 mai 1970) sous l'autorité de la troisième partie de la Loi des compagnies a changé son siège social du 88 Côte de la Montagne au-Palais Montcalm, 975 Place d'Vouville.Le secrétaire général, Jean-Paul Dubreuil.54352-0 1132-70 LE THEATRE DU TRIDENT Notice is given that \"LE THEATRE DU TRIDENT\", incorporated on March 17, 1970, (registered on May 12, 1970) under Part III of the Companies Act.has transferred its head office from 88 Côte de la Montagne, to Palais Montcalm, 975 Place d'Vouville.Jean-Paul Dubreuil, Secretary General.54352 1132-70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1973, 105' année, n° U 6493 TRAC ADIE INVESTMENT LTD.La compagnie «TRACADIE INVESTMENT LTD.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 200, rue Ramesay, Sorcl, au numéro 645, route Marie-Victorin.Tracy.Le secrétaire, Armand Lanciaui.t.54353-0 11310-51 L'NILAB inc.La compagnie « UNI LAB INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 972, Poirier, Mc-Masterville, à Montréal.Le secrétaire, Antonio M.Chôma.54354-0 726095 WEGMA INVESTMENTS inc.Avis est donné que la compagnie « WEGMA INVESTMENTS INC.', constituée en corporation par lettres patentes en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies le 5 novembre 1969, et ayant son siège social en les ville et district de Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui à la suite 1536, 1 Place Ville Marie, Montréal, Québec, l'a transporté à la Suite 1734, 1 Place Ville Marie, Montréal, Québec, aux soins de Mes Sehngcr, Robert & Lengvari.Montréal, le 5 septembre 1973.(Sceau) Le Secrétaire, 54355-0 George Lengvab.1.TRACADIE INVESTMENT LTD.Notice is given that \"TRACADIE INVESTMENT LTD.\" has transferred its head office from 200 Ramesay Street, Sorel, to 645 Marie-Victorin Road, Tracy.Armand Lanciault, Secretary.54353 11310-51 UN I LAB INC.Notice is given that \"UNILAB INC.\" has transferred its head office from 972 Poirier, McMasterville, to Montreal.Antonio M.Chôma, Secretary.54354 726095 WEGMA INVESTMENTS INC.Notice is hereby given that \"WEGMA INVESTMENTS INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patent dated November 5th, 1969, has moved its head office from Suite 1536,1 Place Ville Marie, Montreal, Québec, to Suite 1734, 1 Place Ville Marie, Montreal, Québec, care of Mes Selinger.Robert & Lengvari.Montreal, September 5th, 1973.(Seal) George Lengvari, 54355-0 Secretary.Ministère des Terres et Forêts Cadastre Department of Lands and Forests Cadastre Paroisse de Saint-Féréol Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Féréol, municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges,*, division d'enregistrement de Montmorency.Avis est par la présente donné que le lot 513-6 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 12 octobre 1973./'our le sous-ministre, 54394-0 Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Saint-Jean-Chrysostome Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jean-Chrysos-tome, municipalité de la ville de Charny, division d'enregistrement de Lévis.Avis est par la présente donné que les lots 243-59 à 243-67 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 10 octobre 1973.Pour le sous-ministre, 54394-0 BenoIt Grimard, a.-g.Parish of Saint-Féréol Official cadastre of the parish of Saint-Féréol, municipality of Saint-Féréol-les-Neiges\", registration division of Montmorency.Notice is hereby given that lot 513-6 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 12, 1973.BenoIt Grimard, a.-g., 54394-0 For the Deputy Minister.Parish of Saint-Jean-Chrysostome Official cadastre of the parish of Saint-Jean-Chrysostome, municipality of the town of Charny, registration division of Levis.Notice is hereby given that lots 243-59 to 243-67 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 10, 1973.Benoît Grimard, a.-g., 54394-o For the Deputy Minister. 6494 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Canton d'Ascot Cadastre officiel du canton d'Ascot, municipalité de la cité de Sherbrooke, division d'enregistrement de Sherbrooke.Avis est par la présente donné que la partie restante du lot 15i-682 du rang X.est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 10 octobre 1973.Pour le .iou.s-mini.ilre.54394-o Benoît Grimard, a.-c.Canton de Tremblay Cadastre officiel du canton de Tremblay, municipalité de la cité de Chicoutimi-Nord.division d'enregistrement de Chicoutimi.Avis est par la présente donné que les lots 27-lt-lOH et 27-B-109 du rang III, sont annulés en vertu île l'article 2174a du Code civil.Québec.le 16 octobre 1973.Pour le .iou.i-mini.ilre.54394-0 Bkxoît Grimard, a.-is.Paroisse de Notrc-Dame-du-.Monl-Carmel Cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.municipalité du village de Saint-Georges, division d'enregistrement de Shawinigan.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 1024-49 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 16 octobre 1973.Pour le tous-ministre, 54394-0 Bkxoît Giii.makii.a.-g.Paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoinc-de-Longueuil.municipalité de la ville de Longueuil, division d'enregistrement de Chambly.Avis est par la présente donné que les lots 04-746 n 64-749, 64-741-2.64-741-3.et qu'une partie des lots 64-741, 64-745 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 9 octobre 1973.Pour le .iou.i-niiui.ilre.54394-0 Bkxoît Grimard.a.-u.Village de Bassin-de-Chambiy Cadastre officiel du village de Bassin-de-Chambly.municipalité de la cité de Chambly.division d'enregistrement de Chambly.Avis est par la présente donné que les lots 74-10 ii 74-17 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 15 octobre 1973.Pour le sous-ministre.54394-0 Bkxoît Grimard, a.-g.Township of Ascot Official cadastre of township of Ascot, municipality of the city of Sherbrooke, registration division of Sherbrooke.Notice is hereby given that the remaining part of lot 15Ï-682 of range X, is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 10.1973.Bkxoît Grimard.a.-g., 54394-1) For I he Deputy Minister.Township of Tremblay Official cadastre of township of Tremblay, municipality of the city of Chicoutimi-N'ord, registration division of Chicoutimi.Notice is hereby given that lots 27-B-108 and 27-B-109 of range III are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.October 16.1973.Bkxoît Grimard, a.-g., 54394-0 For the Deputy Minister.Parish of Notre-Dame-du-Mont-Carmel Official cadastre of the parish of Notre-Dame-du-Mont-Carmel.municipality of village of Saint-Georges, registration division of Shawinigan.Notice is hereby given that a part of lot 1024-49 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 10, 1973.Bexoît Grimard, a.-g.54394-0 For the Deputy Minister.Parish of Saint-Antoine-dc-Longueuil Official cadastre of the parish of Saint-Antoine-dc-Longueuil.municipality of the town of Longueuil, registration division of Chambly.Notice is hereby given that lots 64-746 to 64-749, 64-741-2.64-741-3 and that a part of lots 64-741, 64-745 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.October 9.1973.Bkxoît Grimard.a.-g.54394-0 For the Deputy Minister.Village of Bassiii-de-Chanibh Official cadastre of village of Bassin-de-Chambly, municipality of the city of Chambly, registration division of Chambly.Notice is hereby given that lots 74-10 to 74-17 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 15, 1973.Benoît Grimard, a.-g., 54394-0 For the Deputy Minister. GAZETTE 0EIC1ELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1973.105- année, n\" U 6495 Canton de Campbell Cadastre officiel du canton de Campbell, municipalité de la ville de Mont-Laurier, division d'enregistrement de Labelle.Avis est par la présente donné que le lot 33 du rang I est ajoute et qu'une partie des lots 22B et 23A du rang I sont annulées en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 5 octobre 1973.l'our le sous-ministre.54394-o Benoît Ghimahd.a.-W.Township of Campbell Official cadastre of township of Campbell, municipality of the town of Mont-Laurier, registration division of Labelle.Notice is hereby given that lot 33 of range 1 is added and that a part of lots 22B and 23A of range I are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.October 5.1973.BknoIt Gkimakd.a.-g.54394-0 For the Deputy Minister.Curatelle publique Public Curatorship Succession de Roland Duchesne Succession dc Roland Duchesne, en son vivant de 5420, boul.I'ie IN.Montréal, Que.décédé le S mai 1972.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitie SI des lois du Québec 1971), il est administrateur «l'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement île toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.I.k Cl hatkiii public Kl Ql kiikc 9310, boul.St-Lanrent.Montréal 354.Que.H2N 1X6 54426- Kstatc of Roland Duchesne Estate of Roland Duchesne, during his lifetime of 5420 Pius IX Boulevard.Montreal, Québec, who died on May 8.1972.Under the authority of the Public Curatorship Act.(Statutes of Québec.1971.Chapter 81).the undersigned gives notice that he is curator ex officio to this estate and that be will receive payment of any debt owing to this estate and will evidence any claim against said estate at the address given below.The Public Ci iiatoii ok Quebec 9310 St.Laurent Boulevard.Montreal 354.Quebec.112N 1X6 54426 Société d'habitation du Québec Québec Housing Corporation OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION D'ORMSTOWN MUNICIPAL HOUSING BUREAU OF ORMSTOWN Avis est donné qu'en vertu de l'article 55 de la Loi île la Société d'habitation du Québec (chapitre 55 des lois de 1966-1967), le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand seeau de la province, des lettres patentes, en date du dix-septième jour de septembre 1973, constituant en corporation sans but lucratif: .fol¦ ti R.Whitehead, vétérinaire; Maurice Filion, contremaftie: Huntley Greig, cultivateur; Jean-Paul Riendeau.cultivateur; James Winter, rentier: Madame Mona Mason, ménagère; Allan Cavers, rentier, tous domiciliés au village d'Ormstown; pour les fins suivantes: acquérir, construire et.administrer des immeubles d'habitation à loyer modique pour personnes à faible revenu.Le siège social de la corporation est situé dans les limites du territoire du village d'Ormstown.district judiciaire de Beauharnois.Société d'habitation du Québec.Le secrétaire.54415-o Me Jean-Luc Lesage, notaire.OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION D'ORMSTOWN MUNICIPAL HOUSING BUREAU OF ORMSTOWN Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1967, Chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, bearing date of the seventeenth day of September 1973.incorporating as a non-profit coriioration: John R.Whitehead, veterinary: Maurice Filion.foreman; Huntley Greig, farmer; Jean-Paul Ricndeau.fanner: James Winter, retired; Mrs.Mona Mason, house-wife; Allan Cavers, retired, all are living in Ornstown village: for the following purposes: to acquire, to construct and to administer low rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the territory of the municipality of Ormstown village, judicial district of Beauharnois.54415-0 Québec Housing Corporation.Me Jean-Luc Lesage, notary.Secretary. 6496 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 3.1973.Vol.105, No.U Régie de l'assurance maladie du Québec Québec Health Insurance Board Lisle par région de noms et adresses d'affaires des professionnels de la santé, qui entendent exercer leur profession en dehors des cadres du régime en qualité de professionnels désengagés ou de professionnels non participants ou qui ont cessé d'exercer leur activité en cette qualité, ainsi que la date à laquelle prend effet leur désengagement ou leur non-participation ou la cessation de celle-ci, publiée conformément à l'article 7.01 des règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie, adoptés par arrêté en conseil No 27, en date du 6 janvier 1971.Professionnels désengagés Professionals withdrawn Médecins omnipraticiens General Practitioners List compiled on a regional basis, of the names and business addresses of professionals who intend practising their profession outside the scope of the plan as professionals or who have ceased to practice in this capacity, as well as the date on which their withdrawal or non-participation becomes effective or ceases to become effective, published according to section 7.01 of the regulations respecting the Health Insurance Act adopted bv order in council No.27, dated January 6, 1971.Date effective du désengagement Effective date of withdrawal Région de Montréal \u2014 Montreal Region Duchesne, Laurent, 75, boul.Dorchester ouest, Bureau 1017, Montréal 128, (Québec) 29-01-71 Région de Québec \u2014 Québec Region Mino, Roland, Case postale 7395, Québec 7 (Québec) 30-05-71 Tremblay, Jacques, 590, Saint-Cyrille ouest, Québec 6, (Québec) 23-05-71 Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Cbamard, John McLean, 1509, Sherbrooke West, Stite 18A, Montréal 109, (Québec) 16-08-72 Région de Témiscamingue \u2014 Témiscamingue Region Bellehumeur, Claude, 10 rue McQuaig est, Ronyn, (Québec) 08-06-72 Professionnels non participants Non - pa rl ici pat in g proftenon al s Date effective de non-participation Effective date of non-participation Médecins spécialistes Medical Specialists Région de Montréal \u2014 Montreal Region Almudevar, Manuel, 612, St.John's Road, Suite 114, Pointe-Claire 720, (Québec! 01-12-70 Aronovitch, Michael, 4119, Sherbrooke Street West, Montréal 215, (Québec) 01-12-70 Barker, Charles S-, 9, Nelson, Montréal 263, (Québec) 01-12-70 Black, Donald Kenneth, Case postale 95, Hudson Heights, (Québec) 01-12-70 Bossé, Jean, 6555, boul.Gouin ouest, Montréal 389, (Québec) 24-09-72 Boulanger, Jean-Baptiste, 3610, avenue Atwater, Montréal 109, (Québec) 16-04-71 Brabander, Joachim, 1390, Sherbrooke Street West, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Brow, Georges-Raymond, 1374, Sherbrooke Street West, Suite 7, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Browman, Mark, 7841 - 2nd Avenue, Montréal 455, (Québec) 30-07-71 Butler, Albert-A., Medical Arts Bldg., Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Cantero, Antonio.1396.Sainte-Catherine ouest, Montréal 107, (Québec) 01-12-70 Caplan, Ronald-M.1390.Sherbrooke Street West, #2.Montréal 109.(Québec) 01-12-70 Copping, Gordon A., 724, Upper Belmont Avenue, Montréal 217, (Québec) 01-12-70 Cordeau, Claire, 1392, Jean-Talon est.#301, Montréal 329, (Québec) 06-01-73 David, Paul-P., 8705, rue Barbeau, Montréal 457, (Québec) 01-12-70 Dawson, Howard L-, 14, Bellevue Avenue, Westmount 217, (Québec) 01-12-70 Dumais.Gaston, 12245, Grenet, Suite 112, Montréal 390, (Québec) 27-03-71 Eakin, W.W., 1538, Sherbrooke Street West, Apartment 704, Montréal 109, (Québec) 15-01-71 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973.105' année, n' U 6497 Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participation Médecins spécialistes Medical specialists Région de Montréal \u2014 Montreal Region Fullerton, C.W., 1414, Drummond Street, Montréal 107, (Québec) 01-12-70 Gélinas, André, 565, Javelin, Dorval 740, (Québec) 01-12-70 Genest, Armand, 30, boulevard St-Joseph est, Suite 818, Montréal 151, (Québec) 29-01-71 Gold, Michael M.A., 5785, Côte des Neiges, Apartment 105, Montréal 249, (Québec) 01-12-70 Hunt, Brian R., 1538, Sherbrooke West, Apt.622, Montréal 109, (Québec) 03-01-73 Johnston, Kenneth B.Main Road, Hudson, Vaudreuil (Québec) 31-12-70 Korcnberg, l.ela C, 1538, Sherbrooke Street West, #601, Montreal 109 (Québec) 26-08-72 Korenberg, Morton, Medical Arts Bldg., Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Kravitz, Henry, 4994, Circle Road, Montréal 248, (Québec) 10-06-72 Larivière, Paul, 3484, avenue Laval, Montréal 130, (Québec) 01-12-70 Legendre, J.-Henri, 969, boul.Saint-Joseph est.Appartement 3, Montréal 176, (Québec) 01-12-70 Levy, Léonard, 3545, Côte des Neiges, app.118, Montréal 109, (Québec) 06-04-73 Macdonald, Allison D., 3550, Côte des Neiges, Suite 110, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 MacFarlane, Malcolm R.1538, Sherbrooke Street West, #601, Montreal 109 26-08-72 (Québec) Maguire, J.Gordon, 4485, Sherbrooke ouest, West mount, Montréal 215 (Québec) 13-02-71 Manseau, J.Arthur, 960, boulevard Saint-Joseph est, Montréal 176, (Québec) 01-12-70 Mason, Edward Halton, 3465, Côte des Neiges Road, Suite 81, Montréal 109, (Québec) 07-01-71 Melhado, Gerald Carlton, 900, Sherbrooke Street West, Montréal 110, (Québec) 01-01-71 Moll, Albert Edward, 3550, Côte des Neiges Road, Suite 570, Montréal 109, (Québec) 25-04-72 Montgomery, Lorne ('., 556.Grosvenor Avenue.Montreal 217 (Québec) 01-12-70 Morin.Paul.680.Saint-Denis.Saint-Hvacinthe (Québec) 01-12-70 Nadler, Norman-J., 4141, Sherbrooke Ôuest,#540, Montréal 215, (Québec) 01-12-70 Naiman, James, 4330, Sherbrooke ouest, Montréal 215, (Québec) 01-03-72 Nerman, Yale, 1115, Sherbrooke West, Suite 1403, Montréal 110, (Québec) 03-01-71 Pearson, Georges J.R., 5715, avenue Darlington, Appartement 1, Montréal 251, (Québec) 01-12-70 Raginskv, Bernard B., 376, Redfern Avenue, Suite 2, Montréal 215, (Québec) 01-12-70 Redmond, Lila, Medical Arts Bldg., #520, Montreal 109, (Québec) 01-12-70 Robert, Paul, 3489.avenue Atwater, Appartement 6, Montréal 109, (Québec) 03-02-71 Scott, W.Clifford M., 1260, McGregor Avenue, Suite 405, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Smith, Clifton Conway, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 1020, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Smith, Frederick Mclver, 3550.Côte des Neiges, Suite 640, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Stein, Samuel.1025 Pine Avenue West, Montreal 112 (Québec) 01-07-72 Tucker, Elric Clifford, 1390, Sherbrooke Street West, Apt.2, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Région de Québec \u2014 Québec Region Lapointc, Donat, 220, Grande-Allée est, app.650, Québec 4, (Québec) 13-01-71 Larue, Lucien, 964, Casot, Québec 6, (Québec) 26-12-70 Parrot, Paul, 1328, avenue des Pins, Sillery, Québec 6, (Québec) 01-12-70 Médecins omnipraticiens General Practitioners Région de Montréal \u2014 Montreal Region Archambault, Paul-A., 2805, Willowdale, Montréal 250, (Québec) 01-05-71 Brouille, Raynald, 3775, Saint-Hubert, Appartement 10, Montréal 132, (Québec) 02-01-71 Chevrefils.Paul-E.7960, Saint-Denis, Montréal 327, (Québec) 13-12-70 Jacques, Elphège.190.rue Principale est.Karnham (Québec) 01-12-70 Gordon, Lionel, 6235A, Lennox Avenue, Montréal 251, (Québec) 15-01-72 Joannette, Jean-Paul, 4930, Mayfair, Montréal 265, (Québec) 01-12-70 Leclaire, Yves, 47S0, Côte des Neiges, Suite 32, Montréal 247, (Québec) 01-12-70 Mayman, Abe, 5845, Côte des Neiges, Suite 690, Montréal 249, (Québec) 17-12-70 Morgentaler, Henry, 2990, Beaugrand, Montréal 429, (Québec) 05-01-71 Ostiguy, Jean-Paul, 450, rue Sherbrooke est, Suite 108, Montréal 132, (Québec) 01-12-70 6498 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3.1973.Vol.IPS, No.U Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participation Médecins omnipraticiens General Practitioners Région de Montréal \u2014 Montreal Region Scott, Benjamin H., 5146, Westbury Avenue, Montreal 248, (Québec) Vines, Norman M., 1452, Bishop Street, Suite 3, Montréal 107, (Québec) Région de Trois-Rivières \u2014 Trois-Rivières Region Marcotte, Gaston, Case postale 457, Cap-de-la-Madeleine, (Québec) Région de Québec \u2014 Québec Region Rinfret, Charles-G., 3179, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, Québec 10, (Québec) Samson, J.W., 725, 68e Rue est, Québec 7, (Québec) Région des Cantons de l'Est \u2014 Eastern Townships Region Grainger, Thomas R., Case postale 1500.John Manvillc Clinic, Asbestos, Rich- 22-07-71 01-12-70 21-10-71 13-12-70 27-07-72 01-12-70 mond (Québec) Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Beaulieu, J.-Édouard, Case postale 148, Saint-Rémy, Napierville, (Québec) 30-03-71 Bieniecki, Irena, 531, Rockland Avenue, Montréal 153, (Québec) 02-09-72 Bourgoin, Jean-Charles, 1248, rue Lajoie, Montréal 154, (Québec) 15-04-71 Bourke, Edward T., 18, Thornhill Avenue, Westmount 217, (Québec) 09-03-71 Boyles, Williams Howard, 1414, Drummond Street, Suite 422, Montréal 107, (Québec) 02-03-71 Burns, Frank Leonard, 1414, Drummond Street, Suite 1022, Montréal 107, (Québec) 13-02-71 Bushell, Winston C, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 1006, Montréal 109, (Québec) 10-02-71 Caplan, Herbert, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 912 - 913, Montréal 109, (Québec) 11-01-73 Casey, Charles-A., 4695, Sherbrooke Street West, Montreal 215, (Québec) 27-03-71 Colle, Albert Joseph, 5253, boul.Décarie, Suite 218, Montréal 248, (Québec) 03-02-71 Coulombe, Roger, 4660, boulevard St-Joseph, Lachine, (Québec) 25-02-71 DeGrandmont, Claude, 4934, rue Adam, Montréal 404, (Québec) 08-04-72 Dundass, Georges M., 4545, Sherbrooke, Montréal 215, (Québec) 03-03-73 Dundass, Roberta Phelps 4545, Sherbrooke, Montréal 215, (Québec) 29-10-73 Elo, James-Thomas, 1414, Drummond Street, Suite 909, Montréal 107, (Québec) 16-02-71 Franklin, Gérald.4078, Gage Road, Montreal 218 (Québec) 19-11-72 Gendron, Roland, 900 Sherbrooke ouest, Suite 12, Montréal 110, (Québec) 07-03-73 Harvey, Robert-F., 1650, Cedar Avenue, Montréal 109, (Québec) 15-04-71 Henry, Donald Ward, 227, Kenaston Avenue, Montreal 305, (Québec) 31-01-71 Kent, Léonard E., 4695, Sherbrooke Street West, Montréal 215, (Québec) 07-04-71 Kutzman, Ernest-Abraham, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 410, Montréal 109, (Québec) 01-02-71 Labelle, Paul, 11,271, Henri d'Arles, Montréal 389, (Québec) 11-08-71 Lafortune, Jean-Paul, 5704, Laurendeau, Montréal 205, (Québec) 13-02-71 Lalanne, Jean-Guy, 719, 1ère Rue, Iberville, (Québec) 17-01-73 Lawlor, Robert, 333, Chemin Reine-Marie, Montréal 247, (Québec) 18-02-71 Lefebvre, Pierre-L, 2225, boulevard Lapinière, Ville Brossard, (Québec) 02-02-71 Litvack, Sylvia M., 5465, Queen Mary Road, Apartment 610, Montréal 248, (Québec) 01-05-71 Muroff, Frederick, 1414, Drummond Street, Suite 1104, Montréal 107, (Québec) 10-03-71 Myles, Thomas A., 1538, Sherbrooke Street West, Suite 412, Montréal 109, (Québec) 01-02-71 Parent, Benoit, Place Victoria, app.808, Montréal 115, (Québec) 23-08-72 Pearson, Hyman H., 4780, Côte des Neiges Rd., Apartment 19, Montréal 247, (Québec) 06-02-71 Poch, Lewis-Neville, 1, Westmount Square, Suite 346, Westmount 216, (Québec) 14-04-71 Rogers, Mervyn Allen, 4300, boulevard de Maisonneuve ouest, Appartement 702, 06-02-71 Montréal 215, (Québec) Rudick, Gérald-S., 4950, Queen Mary Road, Suite 400, Montréal 248, (Québec) 30-01-71 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973.105' année, n° U 6499 Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participation Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Stockwell, William Gordon, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 805, Montreal 109, (Québec) Sykora, Oskar Paul, Dental Clinic, 1660, Cedar, Montreal 109, (Québec) Van Vliet, Jonothan E., 1538, Sherbrooke Street West, Suite 805, Montréal 109, (Québec) Vinet, Ephrem, 426, boulevard St-Joseph est, Montréal 176, (Québec) Weinlander, Gérard H.G., 1650, Cedar, Montreal 109 (Québec) Région de Québec \u2014 Québec Region Boucher, Marc, 1000, Chemin Ste-Foy, Suite 302, Québec 6, (Québec) Région des Cantons de l'Est \u2014 Eastern Townships Region Dugal, Paul-Laurent, 459A, Lindsay, Drummondville, (Québec) Gosselin, Viateur, 854, Belvédère sud, Sherbrooke, (Québec) Laforce, Jacques, 31, King ouest, Suite 310, Sherbrooke, (Québec) Leblanc, Jean-Yves, Case postale 851, Bedford, (Québec) Marcoux, Jean-F-, 448 rue King ouest, app.4, Sherbrooke, (Québec) Olivier, Valmore H., 843, Belvédère sud, Sherbrooke, (Québec) Région de TOutaouais \u2014 Oulaouais Region Proulx, Jacques, 214, boulevard Saint-Joseph, Hull, (Québec) Optométristes Optometrists Région de Montréal \u2014 Montreal Region Breton, Antonio, 1530, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe, (Québec) Pharmaciens Pharmacists Région de Québec \u2014 Québec Region Auger, Raoul, 1606, Rouville, Ste-Foy, Québec 10, (Québec) Lahberté, Jean, Fortierville, Lotbinière, (Québec) Thibault, Urbain, 9926, Royale, Ste-Anne-de-Beaupré, (Québec) Région de Montréal \u2014 Montreal Region Jacques, Elphège, 188 est, rue Principale, Farnham, Missisquoi, (Québec) Jacques, Paul-Léon, 188 est, rue Principale, Farnham, Missisquoi, (Québec) Moisan, Maurice, 3477, Drummond, App.503, Montréal 107, (Québec) Podlog, Charles, 531, Abercorn, Ville Mont-Royal, Montréal 305, (Québec) Venne, Rosario, St-Hippolyte, Cté Terrebonne Région du Bas Saint-Laurent \u2014 Lower St.Lawrence Region Martin, Roch, rue Saint-Edmond, Lac au Saumon, Matapédia, (Québec) Région du Saguenay, Lac St-Jean \u2014 Saguenay, Lake St-John Region Tremblay, Jean-Marie, Case postale 40, Sacré-Coeur-de-Jésus, Saguenay, (Québec) Région du Nord-Ouest \u2014 North West Region Morin, Léo-Paul, Case postale 570, rue Notre-Dame de Lourdes, Ville-Marie, Témiscamingue, (Québec) Surkis, Max, 68, avenue des Pins, Lebel-sur-Quévilion, Abitibi, (Québec) 54420-O 09-03-71 31-01-71 08-03-71 08-02-71 08-10-73 31-01-71 08-02-71 16-05-73 04-02-71 06-02-71 11-04-71 07-02-71 05-05-71 31-12-70 29-06-73 26-10-72 22-09-72 15-09-72 15-09-72 05-01-73 15-03-73 04-04-73 16-09-72 05-10-72 01-10-72 16-11-72 6500 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3,1973, Vol.105, No.U Proclamation Proclamation HUGUES LAPOINTE Canada.Provinde de Québec.[L.S.1 ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À tous ceux qui les présentes verront ou qu'icclles pourront concerner.Proclamation Salit.Attendu que c*est Notre désir et Notre bon plaisir de rencontrer aussitôt que possible le peuple de la province de Québec et d'obtenir son avis exprimé en parlement; A ces causes, sur l'avis du Conseil exécutif de la province de Québec, Nous convoquons par les présentes une nouvelle législature de la Province pour le vingt-deuxième jour de novembre prochain et mandons et ordonnons à ses membres de s'assembler à cette date au palais législatif, en la Ville de Québec.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de la province de Québec.Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de ladite Province.Donné en Notre hôtel du gouvernement, à Québec le vingt-cinquième jour de septembre, l'an de grâce mil neuf cent soixante-treize et de Notre règne le vingt-deuxième.Par ordre.Le secrétaire-adjoint de la chancellerie à Québec, 53791-39-8-0 Jacques Lessard.HUGUES LAPOINTE Canada.Province of Québec.|L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom.Canada and Her other Realms and Territories Queen.Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern.Greeting.Proclamation Whereas We are desirous and have decided to meet as soon as possible the People of the Province of Québec and to have their advice, expressed in Parliament; Therefore, by and with the advice of the Executive Council of the Province of Québec, We do hereby convene a new Legislature of the Province for the twenty-second day of November next, and do command and order the members thereof to meet on such date at the Parliament Buildings, in the city of Québec.In testimony whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of the Province of Québec to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of the said Province.Given at Our Government House, at Québec, on the twenty-fifth day of September, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and seventy-three, in the twenty-second year of Our Reign.By command.Jacques Lessard, Assistant Clerk of the Crown 53791-39-8-0 in Chancery, al Québec.Ministère de l'Education Department of Education Outaouais-Hull Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de la Haute Gatineau et d'annexer, pour les catholiques seulement, la municipalité scolaire d'Outa-ouais-Hull, le territoire suivant: 1.Le canton de Low.2.Le canton d'Aylwin moins les lots 43 à 46 inclusivement et 49 à 52 inclusivement des rangs IX, X et XI.Le 24 octobre 1973.Le ministre de l'éducation, 54293-43-2-0 François Cloutier.Outaouais-Hull Request is made to detach from the School Municipality of Haute Gatineau and to annex, for the Catholics only, to the School Municipality of Outaouais-Hull, the following territory: 1.The Township of Low.2.The Township of Aylwin less lots 43 to 46 inclusive and 49 to 52 inclusive of Ranges IX, X and XI.October 24, 1973.54293-43-2 François Cloutier, Minister of Education. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1973, 105' année, n° U 6501 Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Assurances Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Insurance LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE COMTE DE MISSISQUOI Avis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Attendu que « LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE.COMTE DE MISSISQUOI », a cessé de faire affaires dans le Québec depuis le 31 décembre 1972: Attendu que le président et le secrétaire-trésorier de ladite compagnie ont produit au Service des assurances, le 15 octobre 1973, une déclaration assermentée à l'effet que la compagnie a annulé toutes ses polices, payé toutes ses dettes et distribué son surplus; En conséquence, avis est par les présentes donné que les permis et certificat d'enregistrement de « LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE, COMTE DE MISSISQUOI », sont annulés à compter du 15 octobre 1973.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 15 octobre 1973.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province.Le surintendant des assurances.54291-43-2-0 Rocer-A.Camaraihe MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY OF THE PARISH OF ST.GEORGE OF CLARENCEVILLE, COUNTY MISSISQUOI Notice of Cancellation of Licence and Certificate of Registration Whereas the \"MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY OF THE PARISH OF ST.GEORGE OF CLARENCEVILLE.COUNTY MISSISQUOI\".has ceased to do business in Québec as from the 31st of December 1972; Whereas the present and the secretary-treasurer of the said company have filed, on the 15th of October 1973, with the Insurance Branch, a sworn declaration to the effect that the company had cancelled all its policies, discharged all its debts and distributed its surplus; Therefore, notice is hereby given that the licence and certificate of registration of the \"MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY OF THE PARISH OF ST.GEORGE OF CLARENCEVILLE, COUNTY MISSISQUOI\" are cancelled as from the 15th of October 1973.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 15th of October.1973.For the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province.Roger-A.Camahaire.54291-43-2-0 Superintendent of Insurance.Sociétés coopératives agricoles Cooperative Agricultural Associations SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE STE-HEDWIDGE (Loi des sociétés coopératives agricoles) Avis est donné que la « Société coopérative agricole de Ste-Hedwidge », dont le siège social était situé à Ste-Hedwidge, dans le district électoral de Roverval, a été dissoute le 18 octobre 1973, et ce conformément aux dispositions de la Loi des sociétés coopératives agricoles et de la Loi de la liquidation des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 54407-o Albert Jessop.SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE STE-HEDWIDGE (Cooperative Agricultural Associations Act) Notice is given that \"Société coopérative agricole de Ste-Hedwidge\", which had its head office located in Ste.Hcdwidge, in the Electoral District of Roberval, was dissolved on October 18, 1973, the foregoing in compliance with the provisions of the Cooperative Agricultural Associations Act and the Winding-up Act.Albert Jessop, Acting Deputy-Minister of Financial Institutions, 54407 Companies and Cooperatives. 0502 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Liquidation \u2014 Loi de la CABINES STE-ROSE LIMITEE Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie c CABINES STE-ROSE LIMITÉE ».tenue à Uval, le 1er novembre 1972.il a été résolu que les affaires de ladite compagnie soient liquidées, et que celle-ci soit dissoute, en vertu île la Loi de la liquidation des compagnies el que M.Gaston Ampleman soit nommé liquidateur.Le directeur du -lerricc des compagnies.l'ir.uur, DkhJAKuixk.54371-0 9441-49 LAITERIE CO-OP ( Loi des syndicats coopératifs) Avis est donné que lors d'une assemblée générale sociale des membres du syndicat coopératif « LAITERIE f'O-OP \".tenue à Trois-Pistoles, dans le district électoral de Rivière-du-l-oup.le 15 août 1973, il a été résolu que les affaires de cette coopérative soient liquidées et que celle-ci soit dissoute, ce en vertu des dispositions de la Loi des syndicats coopératifs et de la Loi de la liquidation des compagnies et que MM.Laurent Rioux.Ican-Marc D'Amours et Germain l'ettigrew soient nommés liquidateurs.I* sous-ministre des institutions financières, compagnies el coopéralires (par intérim), 54372-o Ai.hkiit .Ittisor.Winding-Up Act CABINES STE-ROSE LIMITEE Notice is given that at a special general meeting of the shareholders of \"CABINES STE-ROSE LIMITEE\", held in Laval, on November 1.1972.it was resolved that the affairs of this company be wound up, anil that the latter be dissolved, pursuant to the Winding-Up Act.and that Mr.Gaston Amplcman be appointcil liquidator.Pi Kill! K Dksjakdikb, Director of the Companies Service.54371 9441-49 LAITERIE CO-OP [Coopcratirc Syndicates .let) Notice is given that at a special general meeting of the members of \"LAITERIE CO-OP\", held in Trois-Pislolcs.in the Electoral District of Riviêre-du-l.oup, on August 15, 1973.it was resolved that the affairs of said cooperative be wound-up and that the latter be dissolved in conformity with the provisions of the Cooperative Syndicates Act and the Winding-Up Act and that Messrs.Laurent Rioux, Jean-Marc D'Amours and Germain l'ettigrew be appointed liquidators.Albkkt Jessoi'.Acting Deputy Minister of Financial Institutions.54372 Companies and Cooperatives.Ministère des Affaires municipales Department of Municipal Affairs Canada, Province de HUGUES LA POINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth.Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentai lettres concerneront ou qui les verront.Sai.IT.Lettres patentes Attendu que l'article 2 de la Loi de l'organisation municipale de certains territoires (chapitre 54 des lois de 1971) édicté que le lieutenant-gouverneur en conseil peut délivrer des lettres patentes pour constituer en municipalité toute partie du territoire du Québec qui n'est pas comprise dans une municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne et ou.de l'opinion du ministre des affaires municipales, il ne serait pas souhaitable de constituer, dans l'immédiat, une municipalité de ville ou de campagne; ( 'aiiada.Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom.Canada and Her Other Realms and Territories.Queen.Head of the Commonwealth.Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern.Greeting.Letters Patent Wiikukah, under section 2 of the Act respecting municipal organization of certain territories (Revised Statutes of Quebec.Chapter 54, 1971) it is ordered that the Lieutenant-Governor in Council may issue letters patent to constitute as a municii>ality any part of the territory of the province of Québec not comprised in a city, town, village or country municipality, when, in the opinion of the Minister, it would not be immediately desirable to constitute a town or country municipality; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1073, 105' année, n° U 6503 Attendu que cette partie du territoire des comtés de Maskinongé, Saint-Maurice et Champlain, décrite à la description officielle du ministère îles terres et forêts du 21 août 1973, est un territoire non organisé au point de vue municipal; Attendu que, de l'opinion du ministre des affaires municipales, il ne serait pas souhaitable de constituer, dans l'immédiat, pour cettedite partie du territoire, une municipalité de ville ou de campagne; Attendu qu'il y a maintenant lieu de délivrer des lettres patentes pour constituer cettedite partie de territoire en une municipalité distincte sous le nom de « Municipalité de Belleau »: Attendu Qu'il y a lieu que ladite municipalité de Belleau soit régie par le Code municipal: À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3568-73, du 25 septembre 1973, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes qui entreront en vigueur à compter du jour de leur publication dans la Gazelle officielle du Québec, décrétons et ordonnons que le territoire décrit à la description officielle du ministère des terres et forêts, datée du 21 août 1973, comprenant un territoire non organisé au point de vue municipal des comtés de Maskinongé, Saint-Maurice et Champlain soit constitué en une municipalité distincte, en vertu de l'article 2 de la Loi de l'organisation municipale de certains territoires (cha pitre 54 des lois de 1971), sous le nom de « Municipalité de Belleau ».La description de cedit territoire est la suivante: Un territoire situé dans les cantons de Belleau et De Calonne et dans la seigneurie du (ap-de-la-Madeleine.ne faisant actuellement partie d'aucune municipalité locale distincte, dans les comtés municipaux de Maskinongé, Saint-Maurice et Champlain.comprenant les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, lacs, îles, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: Partant du coin ouest du canton de De Calonne; de là, successivement, les lignes et demarcations suivantes: la ligne nord dudit canton et partie de la ligne nord du canton de Belleau jusqu'à la limite sud-ouest du parc de la Mauricie, telle que décrite dans le chapitre 50 des lois de 1972; la limite dudit parc conformément à ladite loi dans une direction de départ sud-est jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 583 du cadastre de la paroisse «le Sainte-Flore; partie de ladite ligne nors-ouest en allant vers le sud-ouest et son prolongement dans le lac Minogami (lac à la Truite) jusqu'à une ligne irrégulière située à mi-distance entre la rive nord-est dudit lac et la rive nord-est d'une île située dans ledit prolongement; ladite ligne irrégulière dans une direction nord-ouest et la ligne médiane du lac Minogami jusqu'à la ligne nord-est du canton de Caxton; partie de ladite ligne nord-est en allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne sud-est du canton de Belleau; la ligne sud-est et partie de la ligne sud-ouest dudit canton jusqu'à la ligne separative des lots 28 et 29 du rang 1 du cadastre Wmëueas this part of the territory of the Counties of Maskinongé, St.Maurice and Champlain.described in the official description of the Department of Lands and Forests dated August 21, 1973, is an unorganized territory from a municipal point of view; Whereas, in the opinion of the Ministerof Municipal Affairs, it would not be immediately desirable to constitute, for this part of the territory, a town or country municipality: Wiieheas it is now expedient to issue letters patent to constitute this said part of territory as a distinct municipality under the name of \"Municipality of Belleau\"; Wiieheas it is expedient that said municipality of Belleau be governed by the Municipal Code; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 3568-73, dated September 25.1973, We have decreed and ordered and, by the present letters patent which shall come into force on the date of their publication in the Québec Official Gazelle, decree and order that the territory described in the official description of the Department of Lands and Forests dated August 21, 1973.comprising an unorganized territory from a municipal point of view of the Counties of Maskinongé, St.Maurice and Champlain be constituted as a distinct municipality, pursuant to section 2 of the Act respecting municipal organization If certain territories (Revised Statutes of Québec, Chapter 54, 1971), under the name of \"Municipality of Belleau\".The description of this said territory is the following: A territory located in the Townships of Belleau and De Calonne and in the Seigniory of ('ap-de-la-Madeleine, ami presently not forming part of any local distinct municipality, in the Municipal Counties of Maskinongé, St.Maurice and Champlain.comprising lots or parts of lots, hlocks or parts of blocks and their present or future subdivisions as well as the roads, highways, lakes, islands, watercourses or parts thereof, the whole comprised within the limits hereinafter described, to wit: Starting at the western corner of the Township of Dc Calonne; thence, successively, along the following lines anil boundaries: the north line of said Township and part of the north line of the Township of Belleau up to the southwest limit of De la Mauricie Park, as described in Chapter 50, Statutes of Québec, 1972; the limit of said park in conformity with the said Act in a starting direction southeast up to the northwest line of lot 583 of the cadastre for the Parish of Ste.Flore; part of said northwest line proceeding towards the southwest and its extension into the Minogami lake (lac à la Truite) up to a broken line located halfway between the northeast shore of said lake and the northeast edge of an island located within said extension; the said broken line in a northwest direction and the median line of Minogami lake up to the northeast line of the Township of C'axton; part of said northeast line proceeding towards the northwest up to the southeast line of the Township of Belleau ; the southeast line and part of the southwest line of said Township up to the dividing line 0504 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U du canton de De Calonne; en référence au cadastre dudit canton, la ligne separative des lots 28 et 29 dans les rangs I, II, III et IV; une ligne droite à travers le lac Sacacomie et les rangs D Nord-Est et D jusqu'au coin nord du lot 7 du rang D: la ligne nord-ouest des lots 7 à 14 du rang D, la dernière prolongée à travers une partie non cadastrée dudit canton jusqu'à la ligne separative des cantons de Peterborough et De Calonne; partie de ladite ligne separative de cantons en allant vers le nord-ouest jusqu'au point de départ; lesquelles limits définissent un territoire ne possédant pas d'organisation municipale locale distincte, dans les comtés municipaux de Maskinongé, Saint-Maurice et Champlain à être érigé en municipalité sous le nom de Iiellcau.QuE ladite municipalité de Belleau soit régie par le Code municipal.Ex roi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles ap|m>ser le grand sceau de Notre province de Québec: témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapoixte, cf., ch., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, eii Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-cinquième jour de septembre en l'année mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre.I.e sous-procureur général adjoint, J.ibro: 1536 Jkax Alahie.Folio: 121 54406-o of lots 28 and 29 in Range I of the cadastre for the Township of De Calonne; with reference to the cadastre of said Township, the dividing line of lots 28 and 29 in Ranges I, II.Ill and IX: a straight line through the Sacacomie lake and Ranges D northeast and D up to the northern corner of lot 7 in Range D; the northwest line of lots 7 to 14 in Range D, the last extending through a non registered cadastral part of said Township up to the dividing line of the Township of Peterborough and De Calonne; part of said Townships dividing line proceeding towards the northwest up to the starting point: Which boundaries describe a territory having no distinct local municipal organization, in the Counties of Maskinongé.St Maurice and Champlain to be constituted as a municipality under the name of Itelleau.That the said Municipality of Belleau be governed by the Municipal Code.Ix testimoxy whereof, We have caused these Our Present letters to be made patent, anil the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed: Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapoixte, p.o., q.c., Lieutenant-Governor of Our Province of Qiiéliec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twenty-fifth day of September in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-three and in the twenty-second year of Our Reign.By command.Je ax Ai.ar.ie, Libro: 1536 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 121 51406 Canada.Province de HUGUES LAPOINTE Québec.|L.S.| ELIZABETH DEUX, par la grace de Dieu.Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Saut.Lettres patentes Attendu que chacun des conseils municipaux de la municipalité de Saint-Eleuthère.comté de Kamouraska, la paroisse de Saint-Pierre-d'Kstcourt, comté de Témiscouata.et la municipalité de Sully, comté de Témiscouata.a adopté un règlement autorisant In présentation d'une requête conjointe au lieutenant-gouverneur en conseil îe priant d'octroyer des lettres |>atentes fusionnant ces municipalités et créant une nouvelle municipalité sous l'autorité de la Loi favorisant le regroupement des municipalités; ( anada.Province of HUGUES LAPOINTE Québec.IL.S.| ELIZABETH THE SECOND, by the (.race of God of the United Kingdom.Canada and Her other Realms and Territories.Queen.Head of the Commonwealth.Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern.Ghekting.Letters Patent WHEREAS the Municipal Councils of the Municipality of St.Eleuthère.County of Kamouraska, of the Parish of St.Pierrc-d'Escourt.County of Témiscouata.and of the Municipality of Sully.County of Témiscouata have each passed a bylaw authorizing the presentation to the Lieutenant-Governor in Council of a joint petition praying him to issue letters patent amalgamating said municipalities and creating a new municipality, pursuant to the Act to promote the regroupaient of municipalities; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n° U 6505 Attendu que les publications requises par la loi ont été faites; Attendu Qu'un exemplaire de la requête conjointe a été transmis au ministre des affaires municipales et à la Commission municipale du Québec; Attendu Qu'une demande d'enquête a été faite à la Commission municipale du Québec, que celle-ci a tenu une audition publique et a fait rapport au ministre des affaires municipales avec ses recommandations, quant à la modification à l'article 9 de la requête conjointe; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 14 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités, île donner suite à la requête conjointe, telle que modifiée dans le sens des recommandations de la Commission municipale du Québec; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3745-73, du 10 octobre 1973, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des affaires municipales, que les présentes lettres patentes soient octroyées, fusionnant la municipalité de Saint-Eleu-thère, comté de Kamouraska.la paroisse de Saint-Pierre-d'Estcourt, comté de Témiscouata, et la municipalité de Sully, comté de Témiscouata, et créant une nouvelle municipalité sous le nom de « Ville de Pohéné-gamook », aux conditions mentionnées dans la requête conjointe telle que modifiée dans le sens des recommandations de la Commission municipale du Québec.Ces conditions sont les suivantes: 1.Le nom de la nouvelle municipalité est « Ville de Pohénégamook; 2.Le territoire de la nouvelle municipalité est celui qu'a décrit officiellement le ministère des terres et forêts le 22 mai 1973; cette description apparaît comme annexe « A » du susdit décret portant le numéro 3745-73, du 10 octobre 1973; 3.La nouvelle municipalité sera régie par la Loi des cités et villes; 4.Jusqu'à la première élection générale, le conseil provisoire sera composé de sept (7) membres.Le maire de la nouvelle municipalité est l'ancien maire de la municipalité de Saint-Eleutbère dans le premier tiers de la durée du conseil provisoire, l'ancien maire de la municipalité de Sully dans le deuxième tiers de la durée du conseil provisoire, l'ancien maire de la municipalité de Saint-Pierrc-d'Escourt dans le troisième tiers de la durée du conseil provisoire.Lorsque l'un des anciens maires des trois (3) municipalités fusionnées est maire de la nouvelle municipalité pendant la durée du conseil provisoire, les deux (2) anciens maires sont automatiquement conseillers.Les conseils de chacune des municipalités existantes avant la fusion choisiront parmi leurs membres quatre (4) autres conseillers dont deux (2) seront désignés parmi les membres du conseil de la municipalité de Saint-Eleuthère, un parmi les membres du conseil de la municipalité de Saint-Pierre-d'Estcourt et un parmi les membres du conseil de la municipalité de Sully.Whereas the publications prescribed by law have been made; Whereas a copy of the joint petition has been transmitted to the Minister of Municipal Affairs and to the Québec Municipal Commission; Whereas a request for an enquiry has been made to the Québec Municipal Commission anil that the latter has held a public hearing and forwarded its report and recommendations to the Minister of Municipal Affairs concerning the modification of section 9 of the joint petition; Whereas it is expedient, under section 14 of the Act to promote the regroupment of municipalities, to act on the joint petition as modified according to the recommendations of the Québec Municipal Commission ; Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 3745-73.dated October 10.1973.We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Municipal Affairs, that the present letters patent be granted, amalgamating the Municipality of St.Eleuthère.County of Kamouraska.the Parish of St.Pierre-d'Escourt, County of Témiscouata and the Municipality of Sully.County of Témiscouata.and creating a new municipality under the name of \"Town of Pohénégamook\", subject to the conditions set forth in the joint petition as modified according to the recommendations of the Québec Municipal Commission.These conditions are as follows: 1.The name of the new municipality shall be \"Town of Pohénégamook\"; 2.The territory of the new municipality shall be the one officially described by the Department of Lands and Forests on May 22, 1973; this description appears in Appendix \"A\" of the aforesaid decree bearing number 3745-73.dated October 10, 1973; 3.The new municipality shall be governed by the Cities and Towns Act: 4.The provisional Council shall be composed of seven (7) members until the first general election.The mayor of the new municipality shall be the former mayor of the Municipality of St.Eleuthère for the first third of the provisional Council's term, the former mayor of the Municipality of Sully for the second third of the provisional Council's term and the former mayor of the Municipality of St.Pierre-d'Escourt for the last third of the provisional council's term.When one of the former mayers of the three (3) amalgamating municipalities is mayor of the new municipality during the term of the provisional council, the two (2) other former mayers authomatically become councillors.The councillors of each of the existing municipalities before the amalgamation shall choose among themselves four (4) other councillors of which two (2) shall be designated among the members of the Council of the Municipality of St.Eleuthère.one among the members of the Council of the Municipality of St, Pierre-d'Escourt and one among the members of the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.IPS, No.U Chaque conseil désignera le ou les membres qu'ils représenteront sur le conseil provisoire de la nouvelle municipalité-, 5.La première séance du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu en la salle de l'Hôtel de Ville de Saint-Picrre-d'Estcourt, sans autre convocation; 6.I.e greffier de la nouvelle ville sera le secrétaire-trésorier de l'ancienne municipalité de Saint-Eleuthère.conformément à l'article 5fl de la Loi favorisant le regroupement des municipalités chapitre 53 des lois de 1071; 7.A compter de la première élection générale, le nombre des membres du conseil de la nouvelle ville sera de six (6); 8.I* territoire de la nouvelle ville sera divisé en trois (3) quartiers nommés comme suit: Saint-Eleuthère, Estcourt, Sully; Chaque quartier a deux (2) sièges numérotés: le quartier de Saint-Eleuthère possède les sièges numéros 1 et 2, le quartier Estcourt possède les sièges numéros 3 et 4, et le quartier Sully possède les sièges numéros 5 et 6; la description technique de chacun des quartiers correspond à celle préparée et signée par Marc Thi-boutot, arpenteur-géomètre, en date du 16 du mois de janvier 1973 et présentée en annexe « B * du présent arrêté pour en faire partie comme si elle était au long reproduite; 9.La première élection générale du maire et îles conseillers aura lieu le premier dimanche de novembre de l'année de l'entrée en vigueur des lettres patentes, si les lettres patentes sont en vigueur avant le premier août de cette année; si elles sont en vigueur après le 1er août de cette année, la première élection générale a lieu le 1er dimanche de novembre de l'année suivante; 10.Les taxes spéciales continueront à être prélevées conformément aux dispositions des règlements d'emprunt adoptés par les municipalités de Saint-Eleuthère, Estcourt et Sully; 11.Les surplus accumulés au fonds général dans chacune des municipalités, s'il y a lieu, au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes, seront dépensés pour des immobilisations dans le territoire pour lequel ils ont été contractés; 12.Les déficits accumules au fonds général dans chacune des municipalités, s'il y a lieu, au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes, demeurent à la charge du territoire pour lequel ils ont été contractés; 13.L'Office Municipal d'Habitation de la municipalité de Saint-Pierre-d'Estcourt devient l'Office Municipal d'Habitation de la nouvelle municipalité; 14.Les dettes concernant le Ministère de la Famille et du Bien-Etre Social, et le Ministère de la Santé de la municipalité de Saint-Pierre-d'Estcourt demeurent à la charge du territoire pour lequel elles ont été contractées; Council of the Municipality of Sully.Each Council shall appoint one or several members who will represent it on the provisional Council of the new municipality; .5.The first meeting of the provisional Council shall be held on the second legal Monday following the coming into force of the letters patent.It shall be held in the Town Hall of St.Pierre-d'Escourt without further notice; 6.The clerk of the new Town shall be the SecreUry-Treasurer of the former Municipality of St.Eleuthère, pursuant to section 5g of the Act to promote the re-groupment of municipalities, Chapter 53 of the Statutes of 1971; 7.As from the first general election, the Council of the new Town shall be composed of six (6) members; 8.The territory of the new Town shall be divided into three (3) Wards named as follows: St.Eleuthère.Estcourt, Sully; Each ward has two (2) numbered seats: the Ward of St.Eleuthère holds seats numbered 1 and 2, the Ward of Estcourt holds seats numbered 3 and 4, and the Ward of Sully holds scats numbered 5 and 6; the technical description of each of the wards is similar to the one prepared and signed by Marc Thiboutot.land-surveyor, dated January 16.1973.and appended hereto as Appendix \"B\" of the present order to form a part thereof as if it had been fully reproduced; 9.The first general election of a mayor and councillors shall be held on the first Sunday of November in the year of coming into force of the letters patent, if the letters patent come into force before August 1st of same year; should they come into force at a later date, the first general election shall take place on the first Sunday of November of the following year; 10.Special taxes shall continue to be levied in conformity with the provisions of the loan bylaws adopted by the Municipalities of St.Eleuthère, Estcourt and Sully; 11.The accumulated surpluses in the general capital of each municipality as the case may be, at the time of coming into force of the letters patent, shall be used for capital expenditure in the territory in which said surpluses have been contracted; 12.The accumulated deficits in the general capital of each municipality, as the case may be, at the time of coming into force of the letters patent, shall remain the responsibility of the territory in which said deficits have been contracted; 13.The Municipal Housing Bureau of the Municipality of St.Pierre-d'Escourt becomes the Municipal Housing Bureau for the new municipality; 14.The amounts due to the Family and Social Welfare Department and to the Health Department of the Municipality of St.Pierre-d'Escourt shall remain the responsibility of the territory in which they have been contracted; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1973, 105' année, n° U 6507 15.Le rôle d'évaluation de la nouvelle municipalité est composé du rôle d'évaluation de chacune des municipalités fusionnées lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes.Le conseil pourra cependant faire reviser les rôles d'évaluation en vigueur lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes jusqu'au dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation; le rôle d'évaluation des trois (3) municipalités fusionnées sera, s'il y a lieu, uniformisé à 100% de la valeur en attendant qu'un nouveau rôle soit fait conformément à la loi; 16.Les biens-fonds imposables de l'ancien territoire de la municipalité de Sully seront exempts de taxes foncières pour les cinq (5) premières années suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes, à l'exception de tout nouveau bien-fonds imposable inscrit au rôle d'évaluation; cependant les contribuables de la municipalité de Sully seront appelés à payer tout taux de taxe foncière générale et spéciale de la nouvelle municipalité en excédant de $0.60 du cent dollars d'évaluation; 17.Les revenus de la taxe de vidanges devront compenser les dépenses de ce service; 18.La nouvelle municipalité devra respecter, dans la composition de toute nouvelle commission, et plus particulièrement d'une Commission d'Urbanisme ou d'une Commission de Loisirs, le principe de la répartition proportionnelle basée sur la population des quartiers Saint-Eleuthère, Sully et Saint-Pierre-d'Estcourt; 19.Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des municipalités fusionnées deviendront la propriété de la nouvelle municipalité; 20.La nouvelle ville deviendra effective selon la loi.15.The valuation roll of the new municipality shall be composed of the valuation roll of each of the amalgamating municipalities the time of coming into force of the lettres patent.The Council may nevertheless request the revision of the valuation rolls in force at the time of coming into force of the letters patent until a new valuation roll is registered; the valuation roll of the three (3) amalgamated municipalities shall be standardized, as the case may be, at 100% of the value until a new roll has been established in conformity with the law; 16.The taxable immoveable property of the former territory of the Municipality of Sully shall be exempted of land-tax for the five (5) first years following the coming into force of the letters patent, save any new taxable immoveables listed on the valuation roll; nevertheless the tax-payers of the Municipality of Sully shall be called upon to pay all special and general land-tax rates of the new municipality over and above 80.60 for each one hundred dollars of valuation; 17.The income from the garbage disposal tax shall compensate the expenses for supplying such service; 18.In the composition of any new commission, and specially that of a town-planning commission or a commission for recreational guidance, the new municipality shall conform to the apportionment method according to the population of the Wards of St.Eleuthère, Sully and St.Pierre-d'Estcourt; 19.All moveable and immoveable property belonging to each of the amalgamating municipality shall become the property of the new municipality; 20.The new Town shall become effective in conformity with the law.Ex foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Té.moix: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapoixte, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce dixième jour d'octobre en l'année mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre, Libro: 1536 Le sous-procureur général adjoint, Folio: 123 Jean Alarie.« Avis de l'octroi des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités.» Le sous-ministre des affaires municipales, 54406-o Richard Beaulieu.In testimony whereof, We liave cause these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed: Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapoixte, p.c,, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this tenth day of October in the year of Our Lord one thousand nine hundred seventy-three and in the twenty-second year of Our Reign.By command, Libro: 1536 Jean Alarie, Folio: 123 Assistant Deputy Attorney General.\"Notice of the issue of the letters patent hereinabove is given in conformity with the provisions of section 16 of the Act to promote the regroupment of Municipalities.\" Richard Beaulieu, 54406 Deputy Minister of Municipal Affairs. 6508 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 3, 1973.Vol.105.No.U Bureau de révision du district de Montréal Conformément à l'article 44 de la Loi sur l'évaluation foncière, j'ordonne que les limites du territoire du district de révision de Montréal du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, soient modifiées pour y inclure le territoire de la ville de Granby.La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1974.Québec, le 16 octobre 1973.Le ministre des affaires municipales.54406-o Victor C.Goi.dblooxi, m.d.Renseignements sur les compagnies Révocation de dissolution Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, en vertu du paragraphe a de l'article 5/de la Loi des renseignements sur les compagnies, qu'il a jugé à propos de faire droit à la demande d'intéressés faite dans les délais légaux à l'effet de révoquer la dissolution de « E.R.ROSS IXC.» dissolution Iel3 octobre 1973 Gazelle officielle No 41, en vertu de ladite loi et qu'il révoque la dissolution île ladite compagnie.En conséquence, ladite compagnie est censée n'avoir jamais été dissoute en vertu de ladite loi, sans préjudice aux droits acquis par toute personne entre la dissolution et la révocation.Le directeur du service des compagnies, 54295-0 Pierre Desjardinh.Syndicats professionnels ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE MONT-ROYAL (toi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopérative donne avis que le 24 septembre 1973.il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnels, sous le nom de « ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE MONT-ROYAL », avec siège social situé à Mont-Royal, district judiciaire do Montréal.Le sous ministre des institutions financières, compagnies el coopératives.Fernaxd Lalonde.54412-o SP; 38-70 Board of Revision of the District of Montreal Pursuant to section 44 of the Real Estate Assessment Act, I herebv order that the limits of the territory of the Montreal District of the Québec Real Estate Assessment Board of Revision be modified to include the territory of the Town of Granby.The present order shall come into force on January 1.1974.Québec, October 16.1973.Victor C.Goldbloom.u.d., 54406 Minister of Municipal Affairs.Companies Information Act Revocation of dissolution The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice, that pursuant to paragraph a of section 5/ of the Companies Information Act, he deemed it advisable to grant the petititon of the interested parties made within the legal time limit, praying to revoke the dissolution of \"E.R.ROSS INC.\" dissolution of October 13.1973, Québec Official Gazelle, No.41 pursuant to the said Act and that he revokes the dissolution of the said company.Consequently, the said company is considered as having never been dissolved under the said Act.without prejudice to the rights acquired by any person between the dissolution and the revocation.Pierre Desjahdixs.54295 Director of the Companies Service.Professional Syndicates ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE MONT-ROYAL {Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, gives notice that on September 24, 1973, he authorized the incorporation of a professional syndicate under the name of \"ASSOCIATION\" DES PROFESSEURS DE MONT-ROYAL\", with head office located in Mont-Royal, Judicial District of Montreal.Ferxaxd Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54412 SP: 38-70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n\" U 6509 SYNDICAT DES METIERS DE LA CONSTRUCTION DE CHARLEVOIX-EST INC.(C.S.D.) (Loi des syndicats professionnels) Le ministre ) for each mile ira\\vllcd.$0.50 4.(a) In the territory comprised within the limits of other county municipalities of the Province of Québec.(b) In the town and city municipalities geographically comprised within the limits of the territory contemplated in paragraph a.(a) minimum departure tariff.$0.60 (6) for each mile travelled.$0.50 5.In the case of all permits of the \"region\" category when a vehicle is equipped with a taximeter.for each minute of waiting $ 0 10 III Taxicabs without taximeters \u2014 Local service for each mile travelled.S 0.50 IV \u2014 Service extérieur IV \u2014 Service outside limits Dans le cas d'une course dont le lieu d'origine ou la In the case of a trip whose point of origin or final destination finale est située à 10 milles ou plus des destination is situated 10 miles or more from the limits limites de la region ou de l'agglomération à laquelle le of the region or conglomeration to which the permit permisse rapporte, ou a plus de 10 milles de la conurba- relates, or more than 10 miles from the conurbation tion dont dait partiel agglomération à laquelle le permis of which the conglomeration to which the permit se rapporte: relates is part: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 106' année, n° U a) Pour un parcours ou une partie de parcours: i) situé à l'est d'une ligne tirée de l'agglomération d'Alma à l'agglomération de l'ouest du Saguenay à la région de St-Siméon-de-Charlevoix-Est; et sur la rive nord du St-Laurent à l'est de cette ligne, ou ii) situé dans les comtés de Témiscamingue et d'Abitibi ou au nord de ces comtés: De 80.40 pour chaque mille parcouru.6) Pour un parcours ou une partie de parcours non compris dans le territoire décrit au paragraphe a: De 80 30 pour chaque mille parcouru.(a) For a route or part of a route : (i) situated on the east of a line drawn from the conglomeration of Alma to the western conglomeration of the Saguenay to the St.Siméon-de-Charlevoix East region; and on the north shore of the St.Lawrence east of said line; or (ii) situated in the counties of Témiscamingue and Abitibi or north of said counties, From 80.40 for each mile travelled.(6) For a route or part thereof not included in the territory described in paragraph a: From 80.30 for each mile travelled.v \u2014 Baptêmes, mariages ou obsèques \u2014 service local Dans le cadre du service local, au lieu des taux et tarifs sus-mentionnés pour le service fourni en vertu de permis de catégorie « ordinaire *, dans le cas d'un baptême, d'un mariage ou d'obsèques, si le requérant en manifeste le désir lors de la réquisition: a) pour un baptême.$15.00 b) pour un mariage.$17.00 c) pour des obsèques.$18.00 v \u2014 Christenings, weddings, funerals \u2014 local service In the case of local service, in replacement of the above-mentioned rates and tariffs for the service provided pursuant to a permit of the \"ordinary\" category, in the ease of a christening, wedding or funeral, where the hirer so explicitly requests: (a) for a christening.$15.00 (6) fora wedding.$17.00 (c) for a funeral.$18.00 vi \u2014 Bagages Dans le cas où le chauffeur de taxi transporte des bagages au début et à la fin d'une même course à un endroit plus éloigné qu'en bordure immédiate du chemin, du consentement ou à la demande du requérant pour la majoration du prix de la course: $ 0.25 par bagage, à compter du deuxième bagage transporté par ce chauffeur de taxi.vii \u2014 Rémunération d'un chauffeur à la commission 40% des recettes brutes.Toute personne intéressée, désirant être entendue, doit formuler une demande en ce sens et la transmettre à l'administrateur, au siège social de la Commission, 880, Chemin Ste-Foy, Québec 6, avant le 15 novembre 1973.Si la Commission des transports du Québec reçoit une demande d'audition dans ce délai, elle procédera à cette audition avant de rendre sa décision et le cas échéant, l'audience publique aura lieu en la salle d'audience No 1, au bureau de la Commission à Montréal, 800 est, boul.De Maisonneuvc.7e étage, le 19 novembre 1973, à 10.00 heures du matin et en la salle d'audience au siège social de la Commission à Québec, le 21 novembre 1973, à 10.00 heures du matin.Québec, le 00 octobre 1973.Commission des transports du Québec, Maurice Ferland, l.l.l., 54297-0 Administrateur.vi \u2014 Baggage In the case where the taxicab driver is required to handle baggage at the beginning and at the end of the same trip to a place further than the immediate side of the road, upon consent or explicit request from the hirer, the increase in the cost of the trip is: $0.25 per baggage, starting with the second piece of baggage carried by such taxicab driver.mi \u2014 Remuneration of a driver on commission 40% of the gross receipts.Any interested person, wishing to be heard, shall file a request to that effect and forward same to the Administrator, at the head office of the Commission, 880 Ste.Fov Road, Québec 6.prior to November 15, 1973.Should the Québec Transport Commission receive an application for hearing within this time limit, it shall proceed with such hearing before rendering its decision and should such be the case, the public hearing shall be held in audience room No.1, at the Office of the Commission in Montreal, 800 De Maisonneuvc Boulevard East, 7th Floor, on November 19, 1973, at 10:00 o'clock in the forenoon and in the audience room at the head office of the Commission in Québec, on No-vember21, 1973, at 10:00 o'clock in the forenoon.Québec, October 00, 1973.Québec Transport Commission, Maurice Ferland, ll.l.54297 Administrator. 6526 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Assemblée nationale Concernant les projets de loi privés qui seront présentés pendant la prochaine session.Conformément aux nouvelles règles de pratique adoptées par l'Assemblée nationale le 21 décembre 1972 et dont un exemplaire peut être obtenu en s'adressant au soussigné: Les projets de loi privés doivent être déposés au secrétariat des commissions avant le jour de l'ouverture de la session.Les documents dont il est fait mention dans le projet doivent être déposés avec celui-ci.Québec, le 1er novemhre 1973.Le secrétaire des commissions.54296-0 Jacques Pouliot.Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis set seront rendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.BEAUHARNOIS Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Beauharnois l TNAME MARIE-REINE LAFLEUR, No 13.238.s commerçante, résidant et domici- \" liée au 348 rue Danis.Salaberry-de-Val-leyfield.district de Beauharnois, requérante, vs EUS-TACHE FORTIER.menuisier, domicilié au 60 rue Fabre.app.2, à Salaberry-de-Valleyfiehl.district de Beauharnois.intimé.« Un terrain portant le numéro quatre-vingt-quatorze de la subdivision du lot numéro quatre-vingt-douze (94-92) des plan et livre de renvois officiels de la paroisse Ste-Cécile.de la contenance de cinquante pieds de largeur sur cent pieds de profondeur, et borné: en front au nord-ouest par une rue, en arrière au sud-est par le lot numéro 92-79, au nord-est par le lot numéro 92-93 dudit cadastre, avec bâtisses dessus construites et portant le numéro civique 348 de la rue Danis à Salaberry-de-Valleyfield.» Pour être vendu au bureau du Shérif.Palais de Justice, à Salaberry-de-Valleyfield, le SIXIEME jour de DÉCEMBRE 1973, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif.Shérif adjoint, Salahcrry-.le-Valleyfield, Thérèse Leblanc.Le 26 octobre 1973.54423-0 National Assembly Concerning private bills which shall be introduced during the next session.In accordance with the new rules of procedure adopted by the National Assembly on December 21st 1972.a copy of which may be obtained from the undersigned : Private bills shall be filed with the Secretariat of Committees before the day of the opening of the session.The documents mentioned in the bill must be filed with it.Québec.November 1st 1973.Jacques Poulict, 54296-0 Secretary of Committees.Sheriff's Sales PUBLIC NOTICE, is herebv given that the under-mentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.BEAUHARNOIS Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Beauharnois /X/fRS.MARIE-REINE LAFLEUR, No.13.238.-) merchant, residing and domiciled at 348 Danis Street, Salaberry-de-Valleyfield.District of Beauharnois.plaintiff, versus EUS-TACHE FORTIER, carpenter, domiciled at 60 Fabre Street, Apt.2.in Salabcrry-de-Valleyfield, District of Beauharnois.defendant.\"A piece of land bearing number ninety-four of subdivision of lot number ninety-two (94-92) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste.Cécile, measuring fifty feet in width by one hundred feet in depth and bounded in front on the northwest by a street, in rear on the southeast by lot number 92-79 on the northeast by lot number 92-93 of said cadastre, with buildings erected thereon bearing civic number 348 Danis Street, in Salaberry-dc-Valleyfield.\" To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House, in Salaberry-dc-Valleyfield, on the SIXTH day of DECEMBER, 1973, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Thérèse Leblanc, Salaberry-de-Valleyfield, Assistant Sheriff.October 26, 1973.54423 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973.105' année, n\" U 6527 G ASPÉ Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec ('our Provinciale \u2014 District de (Jaspé ( T-JERBERT M.BISSOX, entrepreneur No 3186A 11 en puits artésiens de R.R.1, boite l 116, Shigawake, comté de Bonaventure, P.Q., demandeur, vs GERALD BISSON.journalier de Grande Rivière, district de Gaspé, P.Q.défendeur.« Un certain terrain sis et situé dans la Municipalité de Grande Rivière Ouest, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de la Seigneurie de Grande Rivière, comme faisant partie du lot numéro deux cents (200) du premier rang de ladite seigneurie, mesurant 50 pieds de largeur par 200 pieds de longueur, borné au nord par Gérald Bisson, au sud par le boulevard Perron, à l'est par Isidore Lcbreux et à l'ouest par Gérald Bisson.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du district de Gaspé, au Palais de Justice à Percé, LUNDI, le DIX-SEPTIÈME jour du mois de DÉCEMBRE 1973, à DIX heures de l'avant-midi.Percé, le 23 octobre 1973.shérif, 54414-o Jeax Boi'rget.Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Gaspé Division Iles-dc-la-Madeleine ( T A CAISSE POPULAIRE DE HA-No 255.< -L* VRE-AUX-MAISONS, Iles-de-la.I Madeleine, demanderesse, r* Dr.MARCEL PARATTE, résidant à Cap-aux-Meules, Iles-de-la-Madeleine, défendeur.Un certain lopin de terre au cadastre révisé officiel de l'Ile de Cap-aux-Meules, municipalité de Cap-aux-Mcules, division d'enregistrement des Iles-dc-la-Madeleine, connu comme étant le lot mille sept cent dix-sept (1717) tel que cadastré contenant en superficie 13,950 pieds carrés, avec maison dessus construite, circonstance et dépendances.Pour être revendu à la folle enchère, au bureau du re-gistrateur de la division d'enregistrement des Iles-dc-la-Madeleine, au Palais de Justice à Havre-Aubert, I.M., LUNDI, le DIXIÈME jour de DÉCEMBRE 1973, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Palais de Justice, Napoléon Bbiano.Havre-Aubert, I.M.54428-0 GASPÉ 'Fieri Facias de Terris ( 'anada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Gaspé ( T\u2014TERBERT M.BISSON, artesian wells No.3186.\\ *¦ A contractor, of R.R.1, Box 116.Shi- ' gawake, County of Bonaventure, Québec, plaintif, vs GERALD BISSON, journeyman, of (Jrande Rivière, District of Gaspé, Québec, defendant.\"A certain piece of land lying and situate in the Municipality of (Jrande Rivière West, known and described on the official plan and in the book of reference for the Seigniory of (Jrande Rivière, as forming part of lot number two hundred (200) of the First Range of said Seigniory, measuring 50 feet in width by 200 feet in length, bounded on the north by Gérald Bisson, on the south by Perron Boulevard, on the east by Isidore Le-brcux and on the west by Gérald Bisson.\" To be sold at the District of ( iaspé Registry Office, at the Court House of Percé, on MONDAY, the SEVENTEENTH day of the month of DECEMBER, 1973.ar TEN o'clock in the forenoon.Percé, October 23, 1973.Jean Bourget, 54414 Sheriff.Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court\u2014 District of Gaspé Magdalen Islands Division ( T A CAISSE POPULAIRE DE HA-No.255.{ Lj VRE-AUX-MAISONS.Magdalen l Islands, plaintiff, vs Dr.MARCEL PARATTE, residing in Cap-aux-Meules, Magdalen Islands, defendant.A certain piece of land of the revised official cadastre of the Grindstone Island, Municipality of Cap-aux-Meules, Magdalen Islands Registration Division, known as lot one thousand seven hundred seventeen (1717) as registered in the land-register, covering a surface area of 13,950 square feet, with the house erected thereon, appurtenances and dependencies.To be sold by false bidding at the office of the Registrar for the Magdalen Islands Registration Division, at the Court House in Havre-Aubert, M.I., on MONDAY, the TENTH day of DECEMBER.1973, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Napoleon Briand, Court House, Assistant Sheriff.Havre-Aubert, M.I.54428 6528 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U MÉGANTIC Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Mégantic / pAISSE POPULAIRE D'INVERNESS, No 6608a ' corps légalement constitué ayant une ' place d'affaires à Inverness, demanderesse, i.v GAÉTAN ET (iUYMON'D CHAMPAGNE, tous deux de St-Jean-de-Brébeuf.défendeurs.« Une propriété située au village île St-Jean-de-Brébeuf, comté de Mégantic.dans le onzième rang du canton d'Irlande, du côté sud-ouest de la nouvelle route, mesurant deux cents pieds (200') de largeur le long de ladite route et cent vingt-cinq pieds (125') de profondeur dans sa ligne sud-est, cette dernière étant perpendiculaire à la route, connue au cadastre officiel du canton d'Irlande comme étant une partie du lot numéro sept cent deux (Ptie No 702) borné en front, au nord-est à la route, en arrière, au sud-ouest, et d'un côté sud-est.au résidu d'une partie du même lot.appartenant à Gaétan Champagne, et à l'ouest à la jonction des deux routes, finissant en pointe.Avec le garage dessus construit, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division de Thetford.à Thetford-Mines.le QUATRIÈME jour de DÉCEMBRE 1973.à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Jean-Louis Lalliek.Thetford Mines, ce 18 octobre 1973.54429-o MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( \"DANQUE D'ÉPARGNE DE LA No 05-007205-73A *-> CITÉ ET DU DISTRICT l DE MONTRÉAL, demanderesse.contre TORENO HOMES INC.& AL, défendeurs et LE REGISTRATEUR de Montréal et DAME SYLVANA PORCONO ANELLO, mis en cause.« Ce certain emplacement ayant front sur le boulevard Yiau en la cité de St-Léonard.province de Québec, et composé du: 1.Lot numéro trois cent sept de la subdivision du lot originaire numéro trois cent quatre-vingt-cinq (385-307) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Sault-au-Récollet, mesurant 50.0 pieds en largeur sur S5.0 pieds de profondeur.2.Lot numéro un de la subdivision du lot numéro trois cent huit de la subdivision du lot originaire numéro trois cent quatre-vingt-cinq (385-308-1) auxdits plan et livre de renvoi officiels, et mesurant 7.0 pieds en largeur sur 85.0 pieds en profondeur.MÉGANTIC Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Mégantic l pAISSE POPULAIRE D'INVERNESS, No.0608a 1 a body legally incorporated, having a I place of business in Inverness, plaintiff, m GAÉTAN and GUYMOND CHAMPAGNE, both of St.Jean-de-Brébeuf, defendants.\"A property located in the Village of St.Jean-de-Brébeuf.County of Mégantic.in the Eleventh range of the Township of Irlande, on the southwest side of the new road, measuring two hundred feet (200') in width along the said road and one hundred twenty-five feet (125') in depth on its southeast line, the latter being at right angles with the road, known on the official cadastre for the Township of Irlande as being part of lot number seven hundred anil two (Pt.No.702) bounded in front, on the northeast by the road, at the rear, on the southwest and on one side on the southeast by the remainder of part of the same lot.owned by Gaétan Champagne, anil on the west by the junction of the two roads, ending in a pointed shape.With the garage erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To hi sold in the Thetford Division Registry Office, at Thctford-Mines.on the FOURTH day of DECEMBER.1973.at TEN o'clock in the forenoon.Jean-Louis Lallieh, Sheriff's Office.Sheriff.Thetford Mines, this October 18, 1973.54429-0 MONTREAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal CTHE MONTREAL CITY No.05-007205-73.-J 1 AND DISTRICT SAVINGS ' BANK, plaintiff; tw TORENO HOMES INC.& AL.defendants, and THE REGISTRAR of Montreal and DAME SYLVANA PORCONO ANELLO, mis en cause.\"That certain emplacement fronting on Viau Boulevard in the City of St.Leonard, Province of Québec, composed of: (1) Lot number three hundred and seven of the subdivision of original lot number three hundreil and eighty-five (385-307) on the official plan and book of reference of the Parish of Sault-au-Récollet, measuring 50.0 feet in width by 85.0 feet in depth.(2) Lot number one of the subdivision of lot number three hundred and eight of the subdivision of original lot number three hundred and eighty-five (385-308-1) on the said official plan and book of reference, measuring 7.0 feet in width by 85.0 feet in depth. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n° U 6529 Les dimensions ci-dessus mentionnées sont données en mesures anglaises et plus ou moins.Avec une bâtisse en voie de construction portant les numéros civiques 8910.8910A.8912, 8914 et 8916 du boulevard Viau, et dont le mur sud-est est mitoyen.Avec le droit d'avoir une porte de garage, deux fenêtres et deux galeries donnant sur la propriété voisine du côté sud-est et connue comme étant le lot numéro 385-308-2, et avec le droit pour ladite propriété voisine d'avoir une galerie donnant sur la propriété qui est présentement hypothéquée malgré le fait qu'elles soient plus près de la ligne de séparation entre les deux dites propriétés qu'il n'est permis par la loi; avec une servitude de vue réciproque créée par le présent emprunteur comme étant le propriétaire des deux propriétés.Tel que ladite propriété se trouve actuellement, avec tous ses droits, dépendances et circonstances et avec toutes les servitudes actives et passives y rattachées, le tout sans aucune exception ou réserve.* Pour être vendu au bureau du shérif au Palais de justice de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le SEPTIÈME jour du mois de DÉCEMBRE 1973, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Mahtin.Montréal, le 19 octobre 1973.543S3 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Quélice Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T A BANQUE D'ÉPARGNE No 05-005823-73.< *-> DE LA CITÉ ET DU DISTRICT DE MONTRÉAL, demanderesse, vs LE CURATEUR PUBLIC, en sa qualité de curateur à la succession de feu Giuseppe Mas-tropaolo.défendeur, et LE REGISTRATEUR du bureau d'enregistrement de Montreal, mis en cause.« Un emplacement ayant front sur l'avenue Barclay, en la ville de Montréal, connu et désigné sous le numéro deux cent quatre-vingt-quatre, de la subdivision officielle du lot originaire numéro soixante-huit (68-284) des plan et livre de renvoi officiels du village incorporé de la Côte-des-Neiges, mesurant soixante et un pieds de largeur par cent sept pieds et deux dixièmes de pied de profondeur, dans sa ligne sud-ouest, mesure anglaise et plus ou moins.Avec bâtisse et autres dépendances y édifiées portant le numéro civique 3130 de ladite avenue Barclay.Ainsi que le tout se trouve présentement avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit emplacement sans exception ni réserve.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice, en la ville de Montréal.10 est, rue Craig.10e étage chambre 56.le SIXIÈME jour de DÉCEMBRE 1973, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 23 octobre 1973.54427-o All the above measurements are English measure and more or less.With the building thereon in the course of construction bearing civic numbers 8910, 8910A.8912, 8914 and 8916 Viau Boulevard, whereof the southeasterly wall is mitoyen.With the right to have one garage door, two windows and two galleries overlooking the adjoining property to the southeast known as lot number 385-3Ô8-2 and for said adjoining property to have the right to have one gallery overlooking the property herein hypothecated, even though the same are nearer to the division line between said two properties than that allowed by law: a reciprocal servitude of right of view being hereby created by the Borrower herein as being the owner of both properties.As the said property now subsists with all its rights, members and appurtenances thereunto belonging and with all active anil passive servitudes thereto attached, the whole without exception or reservation of any kind.\" To be sold at the Sheriff's Office.Montreal Court House.10 Craig Street East.10th Floor.Room 56.on the SEVENTH day of DECEMBER, 1973.at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Pall St-Mahtin.Superior Court.Assistant Sheriff.Montreal.October 19.1973.54383-0 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quéliec Superior Court \u2014 District of Montreal I THE MONTREAL CITY AND No.05-005823-73.\\ *¦ DISTRICT SAVINGS I BANK, plaintiff, vs THE PUBLIC CURATOR, in his capacity as curator to the estate of the late Giuseppe Mastropaolo, defendant, and THE REGISTRAR for the Montreal Registry Office.mis en cause.\"An emplacement fronting on Barclay Avenue, in the City of Montreal, known and described under number two hundred eighty-four of the official subdivision of original lot number sixty-eight (68-284) on the official plan and in the book of reference for the Incorporated Village of Côte-des-Neiges.measuring sixty-one feet in width by one hundred seven anil two tenths feet in depth on its southwest line, English measure and more or less.With a building and other dependencies erected thereon.Waring civic number 3130 of said Barclay Avenue.As the whole non subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to saiil emplacement, without exception or reservation.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the City of Montreal Court House.10 Craig Street East.10th Floor.Room 56.on the SIXTEENTH day of DECEMBER.1973.at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office.Paul St-Martin.Superior Court.Assistant Sheriff.Montreal, October 23, 1973.54427 6530 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T A BANQUE DE LA NOU-No 05-004759-73.< ^ VELLE ECOSSE, demande- v resse vs CHARLES EDOUARD TREMBLAY, domicilié au 11932 boul.Taylor dans la Ville de Montréal, défendeur.« Un emplacement situe sur le côté sud-ouest de la soixante-troisième avenue à Plage-des-Iles (Eabreville) dans la ville de Laval, de figure irrégulière et composé d'une partie du lot numéro soixante-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent vingt (120 Ptie 66) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Rose, mesurant seize pieds (16') de largeur en front, le long de la 63e avenue, soixante-huit pieds (68') en arrière le long de la Rivière Jésus, par des profondeurs de vingt-cinq pieds et un pouce (25.1') et quatre-vingt-cinq (85') dans ses lignes nord et nord-ouest et des profondeurs de cinquante-quatre pieds (54') et soixante-quatorze pieds et quatre pouces (74.4') dans ses lignes suil et sud-ouest, mesure anglaise et plus ou moins.Ledit emplacement est indiqué par un liséré rouge et les lettres « A, B, C, D, E, F, A » sur un plan préparé par Maurice Desrochers, a.c;.le vingt-quatre août mil neuf cent soixante-six et revisé le quatorze octobre mil neuf cent soixante-six, portant le No M.-4851-5, dont une copie est annexée à l'original de l'acte de vente par Guy Perrault à Charles Edouard Tremblay, reçu devant Me Paul Archambault, Notaire, le quinze juillet mil neuf cent soixante-dix sous le numéro 286565.Ledit emplacement est borné comme suit: en front vers l'est le long de sa ligne « A-F » par la 63ième avenue, en arrière vers l'ouest le long de la ligne « C-D » par la Rivière Jésus, d'un côte vers le nord-nord-ouest le long de ses lignes « A-B » et « B-C » par une autre partie du lot 160-66 appartenant à demoiselle Germaine Péladeau décrite dans l'acte de vente enregistré au bureau d'enregistrement de Laval sous le No 260189, de l'autre côte vers le sud-sud-ouest le long de ses lignes « F-E » et « E-D » par le résidu dudit lot 120-66 appartenant à Guy Perrault.Avec toutes les bâtisses y érigées et notamment à une maison portant le numéro civique 1156 «le ladite 63ième avenue, et tout l'ameublement qui s'y trouve.Ainsi que le tout se trouve présentement, avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit emplacement et notamment sujet à la servitude de passage en faveur «ludit emplacement contre l'emplacement voisin au nord-ouest appartenant à Demoiselle Germaine Peladeau sur une lisière mesurant douze pieds (12') de largeur par une profondeur d'environ vingt-cinq pieds et un pouce (25.1') décrite dans l'acte enregistré à Laval, sous le No 260189 et le droit de stationner une voiture sur ladite lisière.Et avec droit de passage en commun dans les rues montrées sur deux plans préparés par C.C.Lindsay, a.g.Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( THE BANK OF NOVA SCO-No.05-004759-73.< -1 TIA.plaintif, vs CHARLES l EDOUARD TREMBLAY, domiciled at 11932 Taylor Boulevard, in the City of Montreal, defendant.\"An emplacement located on the southwest side of Sixty-third Avenue at Plage-des-Iles (Fabreville) in the City of Laval, of irregular configuration and comprising part of lot number sixty-six of the official subdivision of original lot number one hundred twenty (120 Pt 66) on the official plan and book of reference for the Parish of Ste.Rose, measuring sixteen fed (16') in width in front, along 63rd Avenue, sixty-eight feet (68') at the rear along Rivière Jésus, by twenty-five feet and one inch (25.1') and eighty-five feet (85') in depth on its north anil northwest lines, and fifty-four feet (54') and seventy-four feet and 4 inches (74.4') in depth on its south and southwest lines.English measure and more or less.Said emplacement is indicated by a red line and the letters \"A, B.C.D, E.F, A\" on a plan prepared by Maurice Desrochers.q.l.s.on August twenty-four one thousand nine hundred sixty-six and revised on October fourteen one thousand nine hundred sixty-six.bearing number M.-4851-5.a copy of which is attached to the original of the deed of sale by Guy Perrault to Charles Edouard Tremblay, signed before Me Paul Archambault.notary, on July fifteen one thousand nine hundred seventy, under number 286565.Said emplacement is bounded as follow: in front, towards the east, along its \"A-F\" line by 63rd Avenue, at the rear towards the west along its \"C-D\" line by Rivière Jésus, on one side towards the north-northwest, along its \"A-B\" and \"B-C\" lines, by another part of lot 160-66 owned by Miss Germaine Péladeau.designated in the deed of sale registered in the Laval Registry Office under number 260189.on the other side towards the south-southwest along its \"F-E\" and \"E-D\" lines by the remainder of said lot 120-66 owncil by Guy Perreault.With all buildings erected thereon, and in particular a house bearing civic number 1156 of said 63rd Avenue, with all the furniture installed therein.As the whole presently subsists, with the active and passive apparent or non-apparent servitudes attaching to said emplacement and in particular subject to the servitudes of right of way in favour of said emplacement against the adjoining emplacement on the northwest, owned by Miss Germaine Péladeau on a strip of land measuring twelve feet (12') in width by approximately twenty-five feet and one inch (25.1') in depth designated in the deed registered at Laval under number 260189 and the right to park a car on said strip of land.And with a common right of way in the streets shown on two plans prepared by C.C.Lindsay, l.s\u201e on dated GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre MS, 105' année, n° U 6531 l'un en date du 16 janvier 1936 et l'autre en date du 27 mai 1937, lesquelles portent les numéros suivants: 120-3-1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 18, 36, 73, 74, du même cadastre et aussi sous les numéros 120-64, 65, 67, 70, 71, 76, 84, 106, et 122 du même cadastre et le droit d'accès à la plage en bordure de la Rivière Jésus, sur les lots 120-3-4 et 120-61 et 83 du même cadastre.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, à 155, boul.Je-Me-Souviens, à Laval, P.Q.le CINQUIÈME jour de DÉCEMBRE 1973, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 15 novembre 1973.54408-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T A BANQUE D'EPARGNE DE No 05-003272-73.< J-' LA CITE ET DU DIS- l TRICT DE MONTREAL, demanderesse, vs RENATO CONSTRUCTION LIMITED ET DANIEL BARTEAU.défendeurs et LE REGIS-TRATEUR de la division d'enregistrement de Montréal et DAME HUGUETTE DAIGNEAULT BARTEAU, mis en cause.« Un emplacement ayant front à la rue Yillanelle, à St-Léonard, composé du lot numéro soixante-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre cent quinze (415-67), au cadastre officiel de la paroisse du Sault-au-Récollet.mesurant quarante-deux pieds (42') dans sa ligne sud.quarante-trois pieds (43') dans sa ligne nord, sur une profondeur de quatre-vingt-dix pieds (90'), mesures anglaises et plus ou moins.Avec la propriété y érigée, portant les numéros 6265 et 6267 de ladite rue Yillanelle à St-Léonard dont le mur est mitoyen.Avec et sujet, ledit immeuble, à une servitude réciproque et perpétuelle de droit de vue.tant pour et contre l'immeuble ci-dessus décrit que pour et contre celui situe à l'est, telle que créée, ladite servitude, dans un acte de ce nom par destination de père de famille, reçu devant Me J.-Pierre Guimond, notaire, le vingt-deux avril mil neuf cent soixante et onze (1971) dont copie sera enregistrée incessamment.Tel que le tout se trouve présentement, avec tous les droits inhérents audit immeuble, les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes y rattachées, sans aucune exception ni reserve.» Pour être vendu au bureau du sherif au Palais de Justice en la Ville de Montréal.10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56.le SIXIÈME jour de DÉCEMBRE 1973, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montreal, ce 16 novembre 1973.54384-0 January 16, 1936 and the other dated May 27.1937.bearing the following numbers: 120-3-1.2.3.5.9.10.11, 18.36, 73, 74, of same cadastre and also known under the following numbers 120-64, 65, 67, 70, 71, 76, 84, 106 and 122 of same cadastre and the right of access to the beach along Rivière Jésus, on lots 120-3-4 and 120-61 and 83 of same cadastre.\" To be sold in the Laval County Registry Office.155 Je-Me-Souviens Boulevard, at Laval, P.Q.on the FIFTH day of DECEMBER, 1973, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office Paul St-Mahtin, Superior Court Assistant Sheriff, Montreal, this November 15, 1973.54408 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( '-THE MONTREAL CITY AND No.05-003272-73.< A DISTRICT SAVINGS I BANK, plaintiff, r* RENATO CONSTRUCTION LIMITED AND DANIEL BARTEAU, defendants, and THE REGISTRAR for the Montreal Registration Division and MRS.HUGUETTE DAIGNEAULT BARTEAU, mis en cause.\"An emplacement fronting on Yillanelle Street in St.Léonard, comprising lot number sixty-seven of the official subdivision of original lot number four hundred fifteen (415-67), on the official cadastre for the Parish of Sault-au-Récollet, measuring forty-two feet (42') on its south line, forty-three feet (43') on its north line, hy a depth of ninety feet (90'), English measure and more or less.With the property erected thereon, bearing numbers 6265 and 6267 on said Yillanelle Street in St.Léonard, whose east wall in common.With and subject, the said immoveable, to a reciprocal and perpetual servitude of right of view, as well for as against the immoveable, hereinabove described as for and against the one located on the east side, as created, the said servitude, in a deed of servitude by destination of previous owner, executed before Me J.-Pierre Guimond.notary, on April twenty-two.one thousand nine hundred seventy-one (1971) of which a copy shall be registered forthwith.As the whole now subsists, with all rights inherent to said immoveable, the servitudes active and passive, apparent or unapparent attaching thereto, without any exception or reservation.\" To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House in the City of Montreal, 10 Craig Street East.10th floor.Room 56, on the SIXTH day of DECEMBER, 1973, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, November 16, 1973.54384 G532 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T A CAISSE POPULAIRE ST-Xo 05-013429-72.4 -L< GREGOIRE LE GRAXD.\" demanderesse rs EDMOXD BI-SHARA défendeur et LE REGISTRAÏEUR de la division d'enregistrement de Montréal mis en cause.«Un emplacement situé en la Cité de Montréal, quartier Bordeaux, ayant front sur la rue Bois de Boulogne, et connu comme le lot numéro deux de la resubdivision du numéro un de la resubdivision du lot deux cent quinze de la subdivision du lot originaire numéro trois cent un (Xo 301-215-1-2) aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse San11.au Récollet, mesurant trente-huit pieds de largeur et cent pieds de profondeur mesure anglaise et plus ou moins.Avec tout droits, circonstances et dépendances, et les bâtisses dessus érigées notamment une maison d'Habitation entière détachée portant le numéro civique 11,400 de la rue Bois de Boulogne, cité de Montréal.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le SEPTIÈME jour de DÉCEMBRE 1973, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 17 octobre 1973.54385-0 PONTIAC Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Pontiac / p HAM PLAIN ALUMINUM INC., No 7321a ' corps politique et constitué, dûment ' incorporé en vertu de la loi, ayant sa principale place d'affaires en la ville de Brossard.district île Montréal, demandeur, contre M.HERBY LA-PORTE, agent de Fort-Coulonge, district de Pontiac.défendeur.« Les lots subdivisions treize et quatorze du lot quatorze du premier rang du cadastre du canton de Mansfield, comté de Pontiac.Province de Québec, (14-13 ; 14-14, R.l) avec les bâtisses dessus érigées, qu'il aurait acquis pour taxes, contrat de vente lui en ayant été fait par la Corporation du Comté de Pontiac, S.S.P., le 20-5-1969, enregistré au susdit bureau d'enregistrement, même jour sous le numéro 83679, excluant cependant parties en bordure nord-ouest ces lots, vendue par Herby Laporte au Ministère de la Voirie de la Province de Québec, pour élargissement de la voie publique passant en face nord-ouest de ces lots.» Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( T A CAISSE POPULAIRE ST-No.05-013429-72.< ^ GREGOIRE LE GRAND, l rs EDMOND BISHARA, defendant, and the REGISTRAR for Montreal registration division, mis en cause.\"An emplacement located in the City of Montreal, Bordeaux Ward, fronting on Bois de Boulogne Street, and known as lot number two of resubdivision of number one of the resubdivisoon of lot two hundred fifteen of the subdivision of original lot number three hundred and one (No.301-215-1-2) on the official plan and in the book, of reference for the Parish of Sault-au-Rc-collet, measuring thirty-eight feet in width and one hundred feet in depth, English measure and more or less.With all rights, appurtenances and dependencies, and the buildings erected thereon, particularly a dwelling house entirely detached bearing civic number 11,400 Bois-de-Boulogne Street, City of Montreal.\" To be sold at the Sheriffs Office, in Montreal Court House, 10 Craig Street East.10th Floor.Room 56.on the SEVENTH day of DECEMBER.1973, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, October 17, 1973.54385 PONTIAC Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Pontiac ( p HAM PLAIN ALUMINUM INC.No.7321a * a body politic and corporate, duly ' incorporated according to law, having its principal place of business on the Town of Brossard.District of Montreal, plaintiff versus Mr.HERBY LAPORTE, agent of Fort Coulonge, District of Pontiac, defendant.\"Lots subdivisions thirteen and fourteen of lot fourteen of the First Range on the cadastre for the Township of Mansfield.County of Pontiac.Province of Québec (13-14 and 14-14.Rge.1) with buildings erected thereon, which he is deemed to have purchased at a sale for taxes by deed of sale executed by the Corporation of the County of Pontiac, S.S.P., on May 20, 1969, registered at the undermentioned Resgistry Office on the same day under number 83679, less and to withdraw the parts bordering on the northwest side of these lots which were sold by Herby Laportc to the Department of Roads of the Province od Québec, for the widening of the public road passing along the northwest side of these lots.\" GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1973, 105' année, n° U 6533 Pour être vendus au Bureau d'Enregistrement de la Division de Pontiac, à Campbell's Bay, le DOUZIÈME jour de DÉCEMBRE, 1973, à DIX heures et TRENTE minutes (10:30 a.m.) de l'avant-midi.Bureau du Shérif.District de Pontiac.P.Q.Ce 23 octobre 1973.Le shérif, André Laçasse.54380-O To be sold at the Division of Pontiac Registry Office in Campbell's Bay, on the TWELFTH dav of DECEMBER, 1973, at TEN THIRTY o'clock (10:30 a.m.) in the forenoon.Sheriff's Office.District of Pontiac, October 23.1973.André Laçasse.Sheriff.54380 Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses FORT EDWARD EXPRESS CO., INC.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « FORT EDWARD EXPRESS CO., INC.», a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Jacques Faquin, avocat, 1422 avenue Jacques-I.e-maistre, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 2253 boulevard Taschereau, longueuil, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives, Albert Jessop.54295 PA: 88-73 FORT EDWARD EXPRESS CO., INC.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"FORT EDWARD EXPRESS CO., INC.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Jacques Paquin, lawyer, 1422 Jacques-Lemaistre Avenue, Montreal.The principal office of the company in the Province is at 2253 Taschereau Boulevard, Longueuil, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.54295-0 PA: 88-73 Errata Errata ASTOR CURB SERVICE LTD.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis d'abandon de charte de la compagnie « ASTOR CURB SERVICE LTD.», paru dans la Gazette officielle du Québec du 21 juillet 1973, numéro 29, à la page 4310, en y remplaçant la date de la dissolution : « 30-07-73 » par « 13-01-67 ».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.54295-0 4039-46 ASTOR CURB SERVICE LTD.Notice is given that pursuant to Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice of surrender of charter of \"ASTOR CURB SERVICE LTD.\", published in the Québec Official Gazette on July 21, 1973, number 29, page 4310, by-replacing the date of the dissolution: \"30-07-73\" by \"13-01-67\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.54295 4039-46 « O V A C O » (ASSOCIATION COOPERATIVE) «O V A CO » (ASSOCIATION COOPERATIVE) Avis de liquidation publie dans l'édition numéro 43 du 27 Octobre 1973, page 6282, le titre de l'avis aurait dû se lire: « VACO » (ASSOCIATION COOPERATIVE) au lieu de: « OVACO ».54296-o In the winding-up notice published on page 6282 of issue number 43, dated October 27, 1973, the title of the notice should have read: VACO (ASSOCIATION COOPERATIVE) instead of: OVACO\".54296-o 6534 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1973, Vol.106, No.U INDEX No 44 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices ASSEMBLÉE NATIONALE NATIONAL ASSEMBLY Private bills.6526 Projets de loi privés.ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES COOPERATIVE ASSOCIATIONS Chaîne coopérative «lu Saguenay (La) (Mod.-Ameiid.).0475 AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Centre Sportif Cathédrale (Dissolution).cation Gar-Lan (Québec) ltée.6466 Manoir Clairval (Laterrière) ltée.6466 Martel (A.) & fils ltée.6466 Motel Trois-Pistoles inc.6466 P.L.N.inc.6467 6540 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.M Lettres patentes Letters patent supplémentaires supplementary (suite) (continued) Perron (Normiek) inc.6467 Piedmont Construction Iw.6466 Piedmont Equipment Ltd.6466 Placements Lionel Gravel inc.(Les).6467 Polyclinique Gravel inc.6467 Rayland Inc.6467 Roy (Philippe) Transport Inc.6467 Société gazifère de Hull incorporée.6467 Tremblay & Fils (Rouyn) inc.6467 Twentieth Century Holdings Corporation.6467 Vertefeuille (Claude) inc.6467 Voyages J.B.L.inc.6467 Sieges sociaux Head Offices A.L.I.Sports Inc.6485 Associated Engineers Limited.6485 Brasserie Place Sauvé Inc.6485 Centre d'Accessoires de cuisine pour décorateurs D.K.M.6486 (.'entre de Culture Dialogue Oriental Limitée.6486 Centre d'échange culturel Est-Ouest Inc.6487 Construction Montbert Inc.(Les).6486 (\"orporation Entex.6486 (\"orporation de Recherche S.P.A.(La).6487 D.K.M.Designer's Kitchen Mart Inc.6486 Dawson Auto Parts St.Georges Ltd.6488 Design Workshop Ltd.6487 Drummond Welding and Steel Works Ltd.6488 East-West Cultural Exchange Center Inc.6487 Éditions Flèche Inc.(Les).6488 Entreprises Carol Coulombe ltée (Les).6437 Entreprises Emluc ltée (Les).6489 Fiset (J.G.) Inc.6489 Frédette & Malouin Tire Service Inc.6488 Gra-Cel Ltd.6439 Gra-Cel ltée.6439 Hill Trailers Inc.6492 Industries Drummond Ltée.6490 Ingénieurs Associés Limitée (Les).6485 International Acceptance Corporation.6490 Jardins Prince Arthur Inc.(Les).6490 Meka Automobiles Inc.64S9 Montbert Construction Inc.6436 Pascal-Dawson Limited.6439 De Passillé-Sylvestre Inc.6490 Pelletier & Martin Ltée.6491 Pipobek International Inc.6491 Place St-Martin Inc.6491 Productions Nikki Inc.6491 Québec Expansion Limitée.6491 Québec Expansion Limited.6491 Remorques Hill Inc.(Les).6492 S.P.A.Research Corporation.6487 Sports A.L.I.Inc.(Les).6485 Sirois (Mauril) Limitée.6492 Société d'investissement Pocamar Inc.6492 Théâtre du Trident (Le).6492 Tracadie Investment Ltd.6493 Unilab inc.8493 Wegma Investments Inc.6493 nu LTRI I V PUBLIC PUBLIQUE CURATORSHIP Succession vacante: Vacant Estate: Duchesne.Roland.6495 DEMANDE À APPLICATION LA LÉGISLATURE TO LEGISLATURE Fédération des Commissions scolaires catholiques du Québec (La).;.6454 Québec Federation of Catholic School Commission (The).6454 LIQUIDATION DES WINDING-UP COMPAGNIES \u2014 Loi de la ACT Cabines Ste-Rose limitée.6502 Laiterie Co-op.6502 « O V A C O \" (Association coopérative) (Erratum).6533 QUEBEC ELECTION ACT LOI ELECTORALE DU QUÉBEC Avis concernant une agence de publicité (Article 377).6510 Notice concerning a publicity agency (section 377).6510 MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales Municipal Affairs Belleau.munie.(L.P.).6502 Board of revision of the district of Montreal (Ord.).6508 Bureau de révision du district de Montréal (Ord.).6508 Pohénégamook.ville-town (Fusion-Amalgama- tion).6504 Éducation Education Muiiicipalilê scolaire de: School Municipality of: Outaouais-Hull (Demande-Application).6500 Institutions financières, compagnies et coopératives Assurance: Financial Institutions Companies and Cooperatives Insurance: Compagnie d'assurance mutuelle contre le feu de la paroisse de Saint-Georges-de-Clarence-ville, comté de Missisquoi (Annul.).6501 Mutual Fire Insurance Company of the Parish of St.George of Clarenceville, County Missisquoi (Annul.).6501 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n' U 6541 Richesses naturelles .Va tu ni/ Resources Révocation de concession minière.Revocation of Mining Concession.6509 6509 Terres et forêts Land* and Forests Cadastre: Cadastre: Ascot, canton-township.6494 Bassin-de-Chambly.village.6494 Campbell, canton-township.6495 Notre-Dame-du-Mont-Carmcl, par.6494 Saint-Antoine-de-Longucuil.par.6494 Saint-Féréol.par.6493 Saint-Jean-Chrysostome.par.6493 Tremblay, canton-township.6494 Transports Transport Entretien de routes discontinué.6431 Maintenance of roads discontinued.6431 PROCLAM ATION PROCLA MA TIO\\ Convocation de la Législature.6500 Convocation of the Legislature.6500 Québec Health Insurance Board Régie de l'assurance-maladie du Québec Professionnals withdrawn.6496 Professionnels désengagés.6496 RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPAGNIES Avis de dissolution éventuelle de corporations: COUPAMES INFORMATION ACT Notice of Eventual Dissolution of Corporations: A.B.C.Driveshaft Inc.6367 A.C.Import Inc.6367 Acier Rayno inc.(L').6367 Aetna Mechanical Plumbing Inc.6367 Agence populaire de financement inc.6367 Agence un toit inc.(L').6367 Agences Capitaine Robert Inc.(Les).6367 Agences Cartier-Laurier ltée (Les).6367 Air Thetford limitée.6367 AlcanClub.6367 Americana Motel Corp.6367 Association des amis de la faune de Hull incorporée (L\").6367 Association catholique des enseignants italo- canadiens (L').6367 Association des marchands d'autos britanniques (L')._.6367 Association des marchands de Verdun inc.(L') 3367 Association Monseigneur de Laval (L').5367 Association des Normaliens de Jacques-Cartier inc.(L).6367 Association des parents grecs-orthodoxes (hellénique) de l'école Carlyle.6367 Association des photographes de la presse de Québec (L') .6367 Association des policiers-pompiers de Victo- riaville inc.(L').6367 Association professionnelle des techniciens en loisir du Québec inc.(L').6367 Association des propriétaires de motels de Montréal inc.6367 Association des propriétaires de Ste-Marthe- du-Cap-de-la-Madeleine inc.6368 Association des propriétaires de terrain de camping de la Côte-du-Sud inc.(L').6368 Association sportive de Repentigny inc.6368 Association sportive St-François inc.6368 Association sportive de la ville de Laprairie.6368 Association des ports et loisirs de Vaudreuil- Soulanges inc.(L') .6368 Assurances bougies & associés inc.(Les) .6368 Assurances (i.Lambert inc.(Les).6368 Assurances Harvey & Gagnon inc.(Les) .6368 Au Bouclier de Brennus inc.6368 Au Domaine Joly inc.6368 Au Pied de cochon (1971) inc.6368 Au Vallon forestier (1965) inc.0368 Aux petits Fours inc.6368 Auberge des Montagnais inc.(L').6368 Auto Enterprises Montreal Ltd.6368 Automobile de l'est inc.6368 B.& F.Metal Works Ltd.6368 B & F Realties Co.Ltd.6369 B.T.U.Heating Inc.6368 Billy's Inc.6368 Boucan inc.(Le).6368 Bouchard (Félix) inc.6368 Boucherie Montréal-Nord ltée.6368 Boulangerie Baril inc.6368 Boulangerie Fleury limitée.6368 Boulevard du Carnaval inc.(Le).6368 Boulevard Estates Corp.6368 Bourcier (Jean-Guy) inc.6368 Bourgeois électrique ltée.6368 Bourget Motel Corp.6368 Bourguignons de Joliette inc.(Les).6368 Boussole de Montréal inc.(La) .6369 Boutique du bébé inc.6369 Boutique Franfrcluche inc.6369 Boutiques mes Amis les animaux inc.(Les).6369 Bowie Insurance Agency Inc.6369 Bowling Equipment & Repairs Inc.6369 Bover (Jean) inc.6369 Bradley (D.S.) (Canada) Ltd.6369 Bradner Fur Co.Ltd.6369 Brallnc.6369 Branded Enterprises Limited.6369 Branded Hosiery Sales (Montreal) Ltd.6369 Brault (Pierre E.) inc.6369 Brendan Wood & Associates Ltd.6369 Brenmore Québec Mines Limited.6369 Brenner (Paul W.) inc.6369 Bfesco Import Export Co.Ltd.6369 Bricon Realties Inc.6369 Brique et pierre du Québec ltée.6369 British & American Cars Ltd.6369 6542 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 3, 1973.Vol.105.No.U Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Broadmore Service Corporation.6369 Brome Estates Inc.6369 Bromeridge Ltd.6369 Brome-Shefford Development Co.Ltd.6369 Bross Furs Inc.6369 Brossard (J.V.) Auto Paris Valleyfield inc.6369 Brown Bros.Auto Parts Inc.6369 Brown (Richard M.J Construction Ltd.6369 Brown-Winlow Company Limited.6369 Brunet (Yvan) inc.6369 Bubble Roy Sales and Promotions Ltd.6369 Builders Mortgage Brokers Inc.6369 Burton Cole (Canada) Ltd.6369 Burton (Lawrence) Company Limited.6369 Burton Sales Inc.6369 Business Equipment Limited .'.6369 Buywcll Equipment Co.Ltd.6369 Byway Holding Corp.Ltd.6370 Cabaret chez Maurice inc.6370 Cabaret littéraire Nelligan inc.(Le).6370 Cabaret Loraine inc.6370 Cabimas Investors Inc.6370 Cadeaux Régal Inc.6370 Cadres professionnels inc.6370 Café Casanova inc.6370 Callan Development Inc.6370 Camclair Inc.6370 Camdeb Realties Limited.6370 Camelot Design Associates Inc.6370 Cameo Silks & Draperies Inc.6370 Camp Dan Inc.6370 Camp Hiawatha inc.6370 Camp L'Escale.6370 Camp Saint-Maurice de Duvernay inc.6370 Campunorama inc.6370 Campai Investment Inc.6370 Campeau (Paul) & fils ltée.6370 Camper's Village Ltd.6370 Camping Canadien (Montréal) inc.6370 Camping Havre-des-Iles inc.6370 Camping St-Edmond inc.6370 Canadian Cameo Chime Company Limited .6370 Canadian Hat Frames Ltd.6370 Canadian & International Footwear Inc.6370 Canadian Magnetic Inc.6370 Canadian Moulded Pulp Products Inc.6370 Canadian Youth Boys' Town.6370 Capitol Building Corporation .6370 Capitol Enterprises Inc.6370 ('apian (l.éo L.) & Co.Ltd.6371 Capricorn Productions Ltd.6371 Caravan Construction (1969) Ltd.6371 Carho-Mix of Canada (Québec) ltée.6371 Card! Ltd.6371 Cardinal motel inc.6371 Cardtown Ltd.6371 Car-Ell Holdings Inc.6371 Carette autos (Chicoutimi) ltée.6371 Caribbean Leisure Corporation Inc.6371 Caribou Land Ltd.6371 Carin (JO Sales Corporation.6371 Carlton Housing Ltd.6371 Carmelly Insurance Agencies Inc.6371 Carmen'Realties Inc.6371 Carnaval d'été des Trois-Rivières inc.(Le) 6371 Carnaval de Granby inc.6371 Carnaval de St-Jean inc.(Le).6371 Caroline Creations Ltd.6371 Caron ('reighton ltée.6371 Caron & Guilbault (chauffage) inc.6371 Carosscries isothermes d'Igloo ltée.6371 Carpcc Inc.6371 Carpet Land of Montreal Inc.6371 Carrefour du livre de Lachute.6371 Carrier & frères construction inc.6371 Carrière de Trois-Pistoles incorporée.6371 Carrières de Rimouski inc.(Les).6371 Carrols Holdings Ltd.6371 Carrousel Murdocliville ltée (Le) 6371 Carney Holdings Ltd.6371 Cartier (Jacques) Investments Co.6371 Cartier Metals Corp.6371 Cartier Parking Inc.6371 Cartier Vending Limited.6371 Carvo ltée.6371 Catlielco Systems (Québec) Ltd.6371 Cauchon Se frères ltée.6372 Cave du meuble inc.(1-a).6372 Caveben limitée.6372 Cavendish café inc.6372 Central Management Corporation.6372 Centre auto-neige Templeton inc.6372 Centre marine du Cap inc.6372 Centre récréatif St-Luc inc.6372 Centre de ski et de récréation Château Bleu inc.6372 Century Automotive Corporation.6372 ( 'ercle de bridge « Le Boulevard » inc.6372 Chauffage Roger Fortin inc.6372 Chez Maillot» inc.6372 Cie Bourma ltée (La).6372 Oie de placements Finascom ltée (La).6372 Cinéma golf St-Michel inc.6372 Cloutier Se Bonrassa construction inc.6372 Club de l'Age d'or, Maniwaki.6372 Club îles bricoleurs ébénistes île St-Joseph de Sorel inc.6372 Club de chasse « Clear Brook - d'Ormstown .6372 Club El-Paso inc.6372 Club des francs de Magog inc.(Le).6372 Club du garatiste inc.(Le).6372 Club de golf Cartierville inc.6372 Club intcr-profcssionnel S; Eureka inc.6372 ( 'lub de moto-neige La Tanière inc.(Le).6372 Club optimiste Maisonncuvc inc.6372 Club personnalité Montréal-Maisonneuve.6372 (.'lub Richelieu Gaspé inc.6372 Club de tir de Boucherville inc.6372 Coiffeur pour hommes Yalcartier inc.6372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n° U 6543 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Comfort Carpet Corporation.6372 Comité des loisirs de Saint-Eugène inc.6372 Compagnie Camar ltée.6372 Compagnie de publication trans-gaspésienne ltée.6373 Comptoir d'informations trans-Québec inc.3373 Conseil des loisirs de Cacouna inc.(Le) .6373 Consolidated Bowling Ltd.6373 Construction Form Co.Ltd.6373 Construction lézard inc.6373 Construction Lucerne inc.6373 Constructions Casmar limitée.6373 Constructions Elysée ltée (Les).6373 Continental Maintenance Inc.6373 Corporation du centre Mont Fortin inc.(La).6373 Corporation Mauagex.6373 Corporation du tourisme de Rivière-du-Loup (La).6373 Crédit des marchands inc.6373 Croteau (J.Roméo) ltée.6373 D & D Propane Gas & Oil Inc.6373 Dames auxiliaires de l'hôpital de la Piéta.6373 Dasco ltée.6373 Dasmic Inc.6373 DatacLtd.6373 Datamatic Bookkeeping Service Limited.6373 Datatech Incorporated.6373 Datsun boulevard inc.6373 Dauphin Iron Mines Limited (no personal liability).6373 Davar Construction Inc.6373 Davis-Sismondo Inc.6373 De Laval Holdings & Enterprises Ltd.6373 Deguire (Jean) assurance inc.6373 Dehm Investments Inc.6373 Development Construction Co.Ltd.6373 Développement des Iles Carillon inc.(Le) .6373 Domaine Manseau inc.6373 Donut Boy Inc.6373 Dufresne & Dufresne incorporée.6373 E.M.R.Holdings Inc.6373 E.S.O.N.ltée.6374 Eastern Caterers Ltd.6374 Eastern Freight Forwarders Ltd.6374 Eastern Peat Moss Inc.6374 Éditions cadres ltée (Les) .6374 Elkmen Development Corp.6374 Ellas Construction Ltd.6374 Elraine Realty Corp.6374 Embassy Estates Corp.6374 Embassy Merchandising Mfg.Ltd.6374 Emgo Realty Corp.63i 4 Emde Construction Company Ltd.6374 Empire Electronics Inc.6374 Empire Gem Inc.6374 Enchères Lebrun inc.(Les).6374 EndemaCo.Ltd.6374 Enright (Raymond) et associés ltée.6374 Entreprises Belle Flamme ltée (Us).6374 Entreprises Bourassa limitée (Les).6374 Entreprises Bourgeois inc.(Les).6374 Entreprises Bonrjac Octo limitée (Les).6374 Entreprises Chalifoux & Bastien inc.(Les).6374 Entreprises Daubrée limitée.6374 Entreprises Del-Champ inc.(Ix;s).6374 Entreprises électriques de Gagné inc.(Les).6374 Ent reprises forestières de Stratford inc.(Les).6374 Entreprises Fortin & Villeneuve inc.(Les).6374 Entreprises Galex ltée.6374 Entreprises George Fortin inc.6374 Entreprises M.P.G.Longueuil inc.6374 Entreprises Maurice Bélanger inc.(Les).6374 Entreprises Mono-Royal (1967) inc.(Les)- 6374 Entreprises Morisset inc.(Les).6374 Entreprises de l'Ouest inc.(Les).6374 Entreprises de peinture de Ste-Foy inc.(Les) 6374 Entreprises Ste-Brigitte ltée.6375 Ent reprises de la vallée de l'Outaouais inc.6375 Entreprises Wilkin inc.(Les).6375 Equipements de bureaux Laurentide inc.6375 Étoile de Gaspé inc.(L1).6375 Étoiles de Longueuil inc.(Les).6375 Etrimo inc.6375 Eubios inc.6375 European Agencies Ltd.6375 Fédération des motocyclistes de sentiers du Québec.6375 Fédération des oeuvres paroissiales de Longueuil inc.6375 Fêtes de la St-Jean (Les).6375 Financial Planning Company of Latin America Ltd.6375 Fineway Specialty Inc.6375 Fiorito assurance limitée.6375 First National Building Corp.6375 Fi tzJohn Investments Ltd.6375 F'laming Hearth Investments Ltd.6375 F'lamingo Construction Inc.6375 Fleetwood Development Corp.6375 Fleisher's Woollen Mills Supplies Limited.6375 Fleur de Lys Carpet Co.Ltd.6375 Flexbeton Limited.6375 Foire du livre de Montréal inc.(La).6375 Fondation Carol Brillant inc.6375 Fondation Richelieu (St-Jean) inc.(La).6375 Fonds de charité catholique de Lachine (Le).6375 Fonds métropolitains inc.6376 Fontaine du boulevard ltée (La).6375 F'orestville construction ltée.6375 Forget automobiles inc.6375 Formation sportive Horizon inc.6375 Fortenna Development & Associates inc.6376 Fortune photo studio inc.(La).6376 Foto Canada Publishing Corporation.6376 Four Season Building Maintenance Incorporated.6376 Foy (L.) inc.6376 Foyer Saint-Chrystophe de New Carlisle inc.6376 Foyer Saint-François de Montmagny.6376 6544 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Frama limitée.6376 Fran Rye Investment Corporation.6376 Francibec inc.6376 Franco metal limitée.6376 Frankel inc.6376 Franmiche inc.6376 Franoram ltée.6376 Frantic Investments Inc.6376 Fraternité française.6376 Freegold Management Corp.6376 Freejay Industries Inc.6376 Front des travailleurs unis de Sept-lle s inc.(Le).6376 Frontenac Maintenance Inc.6376 Fruit Cart Ltd.(The).6376 Furtado (Frank) inc.6376 Fusco (Umberto) Enterprise Ltd.6376 Futura Corporation.6376 Future F'urniture Inc.6376 G.G.rénovation & construction (Henri Bou- rassa) inc.6376 G.R.Brick & Stone Work Ltd.6376 Gage Press Limited.6376 Gagnier, Fleury & associés inc.6376 Gagnon et Gélinas inc.6376 Gagnon & Tremblay ltée.6376 Galarts International Ltd.6376 Galerie de la Mascotte ltée.6376 Galeries du Boulevard inc.(Les).6376 Galeries Grand-Portage inc.(Les).6376 Gamelin (.1.) inc.6377 Garage F'ortin inc.6377 Garage Gagné ltée.6377 Garage Marcel Castonguay inc.6377 Garage Maurice & Richard inc.6377 Garage Seville ltée.6377 Garage Universel Piazza inc.6377 Garage Viaduc ltée.6377 Garage Zembri ltée.6377 Gardenia Cleaners and Shirt Laundry Co.Ltd.6377 Gariépy (Philippe) inc.6377 Garncau (Henri) inc.6377 Garon automobiles inc.6377 Gaticn électrique inc.6377 General Foundry Co.Ltd.6377 Gestion Flambeau inc.6377 Goodis (Jack) Enterprises Inc.6377 (iourmet Fine Foods inc.(Le).6377 Gourmet Food Products Ltd.6377 Great Scott Realty Co.Ltd.6377 Grue mobile Saguenay ltée.6377 Guay (Paul-Emile) inc.6377 H.G.Management Enterprises Ltd.6377 Habitations Futura inc.(Les).6377 Halt-Boren Investment Corporation.6377 Head Food Corporation.6377 Hebrew Friendship Group Inc.6377 Higgins (Brian) & Associates Inc.6377 Hôtel La Guadeloupe inc.6377 Hôtesses de Rigaud inc.(Les).6377 Ice Cream Inn Ltd.6377 Imco Enterprise Ltd.63/7 Immeubles B.P.R.inc.(Les).6377 Immeubles Bourdeau inc.(Les).63/7 Immeubles Bruyère inc.6378 Immeubles Gaston inc.(Les).63/8 Immeubles Jacques-Cartier inc.(Les).6378 Immeubles Manseau inc.(Les).6378 Immeubles Trimaur inc.(Les).6378 Importations S.A.N.inc.(Les).6378 Industries Cady ltée (Les).6378 Industries Lucerne ltée (Les).6378 Industries de machinerie ltée (Les).6378 Industries Valcartier inc.(Les).6378 Inter Flora Québec Corporation.6378 International Reinsurance Brokerage Ltd.6378 Italian Express Travel Service Limited.6378 Javelin Enterprises Ltd.6378 Jeune chambre de Causapscal inc.(La).6378 Jobin (Eugène) inc.6378 Jonver Enterprises Inc.6378 Kassin Bros.Inc.\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022.6378 Kenec construction limitée.6378 Kern's Fur Ltd.6378 Key Data Services Inc.6378 Kolson Enterprises Inc.6378 Kotai Music Inc.6378 L.L.Promotions Ltd.6378 L.& L.Realties Inc.6378 L.M.automobile inc.6378 L.M.M.inc.6378 L.& P.Maintenance Cleaners Inc.6378 La Prairie Aircraft Inc.6378 La Salle Tire Casting Ltd.6378 Laboratoire métropolitain d'électroencéphalo- graphie ltée.6378 Laboratoire des spécialités pharmaceutiques et médicaments brevetés inc.6378 Lachine Fruit Inc.6378 Lakefield Corporation.6378 Lakeview Enterprises Inc.6378 (.allemand (Fred A.) construction ltée.6378 Lamex inc.6378 Langelier Boulevard Development Corp.6379 Lave-auto Ste-Foy ltée.6379 Leclair (Gaétan) inc.6379 Leibo Sales Co.Ltd.6379 Leisure Products Inc.6379 Lemay textiles ltée.6379 Lemelin (L.W.) inc.6379 Lerch Enterprises Ltd.6379 Librairie Maisonneuve inc.6379 Ligue des propriétaires de la paroisse de St-Eustache inc.(La).6379 Liqueurs St-Georges limitée.6379 Little Ones' Car Club Inc.(The).6379 Local Metal & Waste Ltd.6379 Location garantie limitée.6379 Loco transport inc.6379 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1973, 105' année, n° U 6545 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Logrume Ltd.6379 Loisirs La Minerve (Les).6379 Lola Printing Inc.6379 Longue-Pointe construction inc.6379 Lorco limitée.6379 Lord Auto Parts Ltd.6379 Lome Electric (Québec) Ltd.6379 Loucam Co.Ltd.6379 Lucerne Finance Corporation Limited.6379 Lulu-Ann inc.6379 Luminex inc.6379 Lussier (Paul) ltée.6379 Lyons Enterprises (Québec) Corp.6379 M.& L.Holdings Inc.6379 M.P.T.Investments Ltd.6379 M.& R.Development Inc.6379 Madonna Novelties Co.Ltd.6379 Mabarani Restaurant Ltd.6379 Main fraternelle de Québec inc.(La).6379 Maison du campeur inc.(La).6379 Maison mexicaine (La Casa Mexicana) ltée (La).6379 Majestic Electric Québec Ltd.6380 Majorettes étoiles de Forestville inc.6308 Malta Italian Restaurant Inc.6380 Mantab Trading Corporation.6380 Maponet inc.6380 Maranet Investment Corp.6380 Marc Shoes Jobbers Inc.6380 Marcheur de Valleyfield inc.(Le).6380 Marcoland Mines Ltd.6380 Marlene Fashion Shops Inc.6300 Marshall Ellis Limited.6380 Martin Brothers Inc.6380 Mat (France) Construction Ltd.6380 Mat-O-Matic Inc.6380 Maulton Holdings (Québec) Ltd.6380 Mauzone (Food) Caterers Ltd.6380 Mediterranean Fisheries Ltd.6380 Megation Corporation Ltd.6380 Metro Catering Service Inc.6380 Metropolitan Mortgage Brokers Ltd.6380 Milrot Investments Limited.6380 Miss de Maisonneuve inc.6380 Modern Painting Contractors Inc.6380 Mont Gale Ski Centre Limited.6380 Montclair automobiles ltée.6380 Monte Carlo Uniforms Inc.6380 Monte Cassino Social Club Inc.6380 Montreal Free School Incorporated (The).6380 Montreal \"Hair\" Company Ltd.6380 Montreal Oil Carriers Inc.6380 Montreal P & L auto ltée.6380 Moonstar Inc.6380 Morav Holding Corp.6380 Morin (E.) & fils inc.6380 Morin (L.P.) et associés inc.6380 Morley Associates Inc.6381 Morocco Investments Inc.6381 Mort Ross Productions Inc.6381 Mosaic Corporation of North America Ltd.6381 Motel Moulin Rouge inc.6381 Motel Le Village inc.6381 Motivex ltée.6381 Motor Holdings Ltd.6381 Motor Home Rental Inc.6381 Mountain Press Ltd.6381.Mountcrest Construction Inc.6381 Mouvement religieux Sepharade.6381 Mozart (Sherbrooke) Limited.6381 National Cable T.V.Co.Ltd.6381 Netto inc.6381 Nettoyeurs Wrightville inc.6381 New Breed Club Inc.(The).6381 New Form Furniture Ltd.6381 Nicomar publicité inc.6381 Nir Investment Inc.6381 Normar Holdings Ltd.6381 North End Development Inc.6381 North End Jewish Business Men's Center Inc.6381 North West Motor Sales Ltd.6381 North-End Service Inc.6381 Northern Foods Inc.6381 Nu'Way Investments Corporation Ltd.6381 Observateur de Laval inc.(L').6381 Office de développement régional de l'Etche- min (L').6381 Organisation des terrains de jeux de Gagnon inc.(L').6381 P.B.Properties Ltd.6381 P and B Construction Inc.6381 P.K.S.Enterprises Ltd.6381 P.L.Flooring Ltd.6381 Pact.6381 Panlaconian Association of Montreal Inc.6381 Papineau Florist Inc.6382 Parallel Petroleum Ltd.6382 Pare Flooring Limited.6382 Park View Realties Brokers Ltd.6382 Pâtisserie Luric inc.6382 Pavillon St-François inc.6382 Perma-lustre inc.6382 Pétroles Brassard ltée (Les).6382 Petroleum Business Services Ltd.6382 Pevee Mountain Development Corporation .6382 Pine Hill Sand and Gravel Inc.6382 Place Longueuil inc.6382 Placements Bro-Long ltée (Les).6382 Placements Bull inc.(Les).6382 Placements Deka Investments Inc.6382 Placements franco-américains ltée (Les).6382 Placements Hibou inc.6382 Placements Lomat inc.(Les).6382 Placements Ix>uise inc.(Les).6382 Placements Lucianne inc.(Les).6382 Placements Quirion inc.(Les).6382 Poissons frais de la Gaspésie inc.6382 Ponderosa Foods Ltd.6382 Poulin & Catellier inc.6382 6546 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 3.1973.Vol.105.No.U Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Prairie Aircraft inc.(I.a).6382 Pripstein's Camp Inc.63S2 Productions Fontaine inc.6382 Productions Gaston l.apicrre inc.(I.es).6382 Produits en hois Lepage inc.(Les).6382 Produits forestiers Lather inc.6382 Produits Moonglow cie ltée (Les) .6382 Produits Tur-Mo inc.(Les) 6382 Provincial Catering Limited .6382 Provincial Fleet Leasing Ltd.6382 Provinciale forme ltée.6382 Publications Le Monde île Ste-Foy inc.6382 Quality Building Maintenance Ltd.6383 Quebec Fragrances Corp.6383 Queen's Garage Ltd.6383 Quintal (M.) inc.6383 R.B.construction inc.6383 U.C.Franchise Broker Ltd.6383 R.D.Design & Seal Inc.6383 R.P.B.construction ltée.63S3 Radio Caplan inc.6383 Renaud & frères inc.6383 Renée Carpet Ltd.6383 Restaurant Le Bouvillon Grillé inc.6383 Restaurant Dauvil inc.63S3 Restaurant de France inc.6383 Restaurant Le Bûcheron inc.6383 Riendcau & Gascon Inc.6383 Robert (Marc) limitée.6383 Ron Mortgage & Investment Cor)).6383 Rona-Froh Ltd.6383 Rousseau (Ste-Foy) inc.6383 Roy (Gaston) Shell Service Inc.6383 Roy (Marcel) & associés inc.6383 Roy-Lou Enterprises Ltd.6383 S.F.Machinery Ltd.6383 S.F.Transport Inc.6383 S.S.Gala Navigation Inc.6383 St.James Gold Mines Limited (no personal liability).6383 St.l^urent sport inc.6383 Saint-François Pec Wee de Sherbrooke inc.(Le).6383 Saguenéens senior inc.(Les).6383 Salaison de Bourget inc.6383 Sarrasin (J.F.) inc.6383 Savers Franchise Corp.6383 Scalia (Rosario) construction ltée.6383 Secretarial Training Centre Ltd.6383 See Europe Tours Inc.6384 Service de cadres hospitaliers inc.6384 Service des loisirs St-Eusèhe de Montréal .6384 Sga Motel Ltd.6384 Sherrick Motors Ltd.6384 Sigi Motors (Montreal) Ltd.6384 Silver Dollar Cabaret Inc.6384 Silver (Leonard) Furs Inc.6384 Sitar (Frank) Inc.6384 Sixtv-five Development Ltd.6384 Snow Fire Industries Ltd- .6384 Société culturelle de Sept-Iles inc.-.6384 Société de formules mécanographiques inc.6384 Société Fortex inc.0384 Société funéraire St-Hyacinthc incorporée .6384 Société Val-Bourg inc.(La).6384 Société zoologique de Malartic inc.6384 Sosner's Y.Cafeteria Ltd.6384 Soudure Saguenay ltée .6384 South shore Flooring Inc.6384 Spectacles sonores du Cap inc.6384 Springer Swiss Embroidery Works Inc.6384 Stanbra Motors Inc.6384 Stardust Cabaret Inc.6384 Stenrose Corp.6384 Stephen (Raymond) Mortgage & Investments Corp.Studio de santé l'Olympe inc.6384 Sun Ware (lx>ngueuil) limitée.6383 Super Maintenance (S.M.) Ltd.6384 Swan Humidifier < ».Ltd.6384 Syndicated Business Borkers Inc.6384 T.F.récréations inc.6384 T.M.paysagistes inc.6384 Taverne Empire liée.6384 Taverne L.& M.inc.6384 Tecumseh Golf and Curling Club (The) .6384 Tcena Caprice Garments Inc.6385 Théâtre pour enfants de Québec inc.6385 Tire Casing Supply Ltd.6385 Touchette (Marcel) & ass.inc.6385 Tracy fleuriste inc.6385 Training Systems for Business Ltd.6385 Transportation Brokers Inc.6385 Tremblay (Gaétan) et associés assurances ltée 6385 Trottier, O'Bready & associés inc.6385 Troupe folklorique « Les Pirouys » inc.(La) .6385 Troupe scoupe St-Louis de Marie de Monfort .(La).6385 Twins Mortgage & Investments Corp.6385 United Film Enterprises Ltd.6385 United Touch Football Association of Montreal.6385 Universal Bookkeeping and Translation Services Inc.6385 Usereau (Gaétan) ltée.\u2022 6385 Y.S.M.Auto Parts Co.Ltd.6385 V.& V.& B.Construction Ltd.6385 Vachon Bus Sales & Manufacturing Limited.6385 Yanguy ltée .6385 Vêtements F.lzéar Fortier ltée (Les).6385 Vida Welding Inc.6385 Vienna Motel Inc.6385 Vieux poste inc.(Le) .6385 Vigeant (Gerard) automobiles inc.6385 Villa Gagnon inc.6385 Villas Laurentides inc.(Les).6385 Villas des pins ltee.6385 Ville Émard sport inc.6385 Walco Motels Ltd.6385 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973.105' année, n' U 6547 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Webro Tool & Mould Mfg.Ltd.6385 West End Ornamental Ine.6385 West Side Bowl Inc.6385 Wilkins (W.M.) inc.6385 Windsor Bowling Stables Inc.6386 Zahav Investment Corporation.6386 Lettres patentes annulées: tellers Patent .Innulled: A.- & I).transport ltée.6386 A.L.D.L.distributeurs ltée.6386 A.P.G.Enterprises Ltd.6386 A.S.S.F.Inc.638e Administradim Inc.6386 Agences Baly assurances inc.6386 Ahuntsic construction ltée.6386 Alarme de sûreté (Montréal) inc.6386 Anglo-French Investments (1966) Corporation 6386 Anoki Fish and Game Club.6386 Aquamex Inc.6386 Aquarius Cleaners Ltd.6386 Artemis Sportswear Ltd.6386 Association des citoyens de la Mauricie (L-).6386 Association des enseignants professionnels de la danse du Québec.6386 Association des entrepreneurs pétroliers du Québec inc.6386 Association des propriétaires de St-Louis de Terrebonne inc.6386 Association des propriétaires de la ville de I.ebel-sur-Quévillon.6386 Association Québec-France des jeunes juristes (AQFJ).0386 Astra services techniques inc.6386 Atelier de formation d'animateur ci.lturel.6386 Atlantic Oil Products Limited .6386 Auberge du cheval blanc inc.6386 Auberge des grèves inc.6387 Audcman Inc.6387 Audet Plastics Specialties Inc.6387 Aunis inc.6387 Auto Port Inc._.6387 Automation de qualité de Montréal inc.6387 Aylmer Rod & Gun Club Inc.6387 Bcauchesnes Club.63S7 Beaudoin (P.& N.) construction inc.6387 Beaver Mining Corporation.6387 Beaver Oil Co.Limited.6387 Bédard (Jean-Marie) inc.6387 Bega Lobster House Inc.6387 Bellerose (Zenon) inc.6387 Bell-Kay Investments Inc.6387 Belvicar ltée.6387 Bibeau (Armand) construction inc.0387 Biske! Investments Inc.6387 Bokor Holdings Ltd.6387 Bonetti (E.) et F.Tenaglia Monuments Inc.6387 Bourassa (Gabriel) inc.6387 Boutique du cadeau norske, incorporée.6387 Brasserie du capitaine inc.6387 Brault (Edouard) inc.6387 Brien (Geo.) inc.6387 Brisson (fourrures) ltée.6387 Brookside Furs Ltd.6387 Brunet & Paquette inc.6387 Butterfly International Inc.6387 ('.P.P.Distributors Services Inc.6387 Cadeaux Le Carillon Inc.6387 Camp iroquois inc.6387 Camping des sportifs inc.6387 Canadian Corps (1914-19) Association in Québec.6387 Canadian Weight Losers Club C W L C Inc.6387 Cantex Chemicals & Equipment Corp.6387 (antin (Gilles) ltée.6387 Cardinal Air Services Limited.6388 Case Exporters Inc.6388 Catrala Québec Inc.6388 Centre de beauté naturiste Lafortune inc.6388 Centre international du cinéma inc.6388 Centre de loisirs de la Pocaticre inc.(Le) 0.3ns Centre St-Jacqucs inc.6388 Cephailonian Brotherhood Society.6388 Cercle combatif contre l'incendie de la province de Quéliec inc.6388 Chamberland (Jos) inc.6388 Champagne (Jean-Marie) inc.63S8 Charbonneau (Alain) inc.6388 Château blanc de Ste-Scholastique inc.(Le).638S Château des monts inc.(Le).6388 Chaussures Bellemarc ltée 0388 Chaussures Gaétan inc.6388 Chaussures Georgio ltée.6388 Citadel Wholesalers Limited.03ss Clément (Edgar) limitée.03ns Club Adam.6388 Club des aigles du lac caché.6388 Club ango incorporée.6388 Club automobile P.C.A.inc.63SS Club automobile Waki.6388 Club automobiles de Beauce inc.03.88 Club auto-neige, lac St-Pierre inc.6388 Club Badeau.6388 Club de Batiscan.6388 Club lielle montagne.6388 Club belle nature inc.6388 Club la belle province.6388 Club le bouc inc.6388 Club de C.& P.Gaspésien inc.6388 Club de C.& P.du lac Elgin de Stratford cté de Wolfe inc.6388 Stratford cté de Wolfe inc.6388 Club cabane F>nest inc.6388 Club la cédrière inc.0388 Club de chasse de la dune inc.638!) Club de chasse & pêche Clément inc.6389 Club Clatro inc.6389 Club Clérion inc.63K9 Club concorde.6389 6548 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, No.U Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: [suite) (continued) Club du cran inc.6389 Club du crick.6389 Club Danse, eau inc.6389 Club Dequen.6389 Club doc inc.6389 ClubDollard.6389 Club Drummond Arthabaska inc.6389 Club epinette rouge.6389 Club Esso inc.6389 ClubFarlay.6389 Club du faucon d'or inc.6389 Club Gar-Lac.0389 Club des gaspards inc.6389 Club Gclbert.6389 Club de golf de Murdochville inc.6389 Club Gonzague.6389 Club Gustave inc.6389 Club de la hache inc.6389 Club Hilfred.6389 Club Hosanna inc.6389 Club de la John.6389 Club juvenile de Laval ouest.6389 Club Kido inc.6389 Club Kue-.Kue inc.6389 Club du lac coco.6389 Club du lac emmuraillc inc.6389 Club du lac Fecteau.6389 Club lac Gérard.6389 Club du lac Isidore.6389 Club du lac Pierre Aubin inc.6389 Club Lasource inc.6389 Club Maskoutain inc.6389 Club optimiste de St-Hyacinthe inc.(Le).6390 Club de pêche et chasse du lac Laurel inc.6390 Club de pêche et de chasse Linière.0390 Club de pêche gourganne.6390 Club de pêche du lac famine inc.6390 Club de protection de la faune du lac Masson inc.6390 Club des quilleurs du Québec (1962) inc.6390 ('lub de sécurité du transport écolier inc.(Le).6390 Clubs de francs, incorporée (Les).6390 Cohen (Samuel E.) Ltd.0390 Coliseum Diversified Holdings Inc.6390 Commercial Litho Plate Graining Ltd.6390 Concept 2887139 ltée.0390 Conseil économique rural de la région 3.6390 Construction Befor ltée.6390 Consumers Printing Supplies Ltd.6390 Cosec construction inc.6390 Cosmetrix Inc.6390 Côté (Patrick) Inc.0390 Côte St-Luc Car Wash Inc.6390 Courtemanchc Équipement Inc.6390 Création de mode Écusson inc.6390 Dairy Barn' Stores of Canada Limited.6390 Decin Investments Inc.6390 Dento inc.6390 Développements des lieaux quartiers ltée (Les) 6390 Distributeurs Montmorency limitée.6390 Distribution capitale ltée.6390 Distributions mini-maxi (Joliette) inc.(Les).6390 District Finance Corporation Limited.0390 Domaine Chambery ltée.0390 Domaine mon plaisir inc.6390 Dorchester Mini-Market Limited.0390 Drapeau (F.) Transport Inc.6390 Dunn's Men's Wear Inc.0390 Dunton Investments Ltd.6390 Durivage Lamarre (André) Productions Inc.6390 g.& M.Promotion Sales Ltd.6391 Ébénisterie Ami inc.6391 Économie sociale ltée.6391 Édifico inc.6391 Éditions l'Action inc.(Les).6391 Editions musicales Barma inc.(Les).6391 Éditions situation inc.6391 Éditions solutions tée (Les).6391 Eflol inc.6391 Egecoltée.6391 Électrosol inc.6391 Entreprises Beaubien inc.6391 Entreprises Buard inc.(Les).6391 Entreprises De Foy inc.(lies).6391 Entreprises Dimco ltée (Les).6391 Entreprises J.M.inc.(Les).6391 Entreprises Pointe Valainc ltée (Les).6391 Entreprises Roland Daiglc inc.(Les).6391 Entreprises St-Adolphe inc.6391 Esquire Realtv Corp.6391 Europe Plastic Moulds.Tools & Dies Ltd.0391 Exeter Investments Ltd.6391 Federal Plastics Ltd.6391 Fédération haltérophile du Québec.6391 Ferco Paints & Machinery Rentals Ltd.6391 Findec Investments Inc.6391 Flash Screen Process Inc.6391 Focal International Inc.6391 Fortin (J.M.E.) inc.6391 Fournitures chirurgicales du Québec ltée.6391 G.L.Optical Industry Inc.6391 G.M.C.Excavation Inc.0391 Gagnon (Marcel A.) & associés inc.6391 Gai logis inc.6391 Gaudrcau (Fernand) inc.6391 Gauthier (A.) & Fils ltée.0391 (icneral Builders Association.6391 Gif Bec ltée.6392 (iita International Inc.6392 Gold Medal Developments Inc.6392 Goodis (A.) inc.6392 Gossclin (J.A.i ltée.6392 (iranow Incorporated.6392 Hampslead Golf Club Inc.6392 Hébert (Guy) inc.6392 Hôtel motel Tapanée inc.6392 Howark Corp.Ltée.6392 Hy Fashion Millinery Inc.6392 Immeubles Beauharnois inc.(Les).6392 Immeubles de la Grand Route inc.6392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1973, 105' année, n\" U 6549 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Immeubles Impérial ltée.6392 Importations Narbonne inc.6392 Importations Taron inc.(Les).6392 Industries Peloquin ltée (Les).6392 Inter-city Commercial inc.6392 Issbro Investments Inc.6392 Jafra inc.6392 Jaymar Construction Ltd.6392 Jeune chambre de la Sarre inc.(La).6392 Joliette plomberie & chauffage inc.6392 Kabigx Ltd.6392 Kibalnc.6392 Kindler (Alex) inc.6392 Knopp's Coiffure Co.6392 Krishna (Aldex) inc.\u2022 6392 Labelle Associates Inc.6392 Laval embellissement ltée.6392 Ligue de ballon sur glace de Victoriaville inc.6392 Ligue des propriétaires de St-Eustache ouest inc.(La).6392 Ligue vieux poêle d'Arvida inc.(La).6392 Lingerie Idéale de Saint-Victor.6392 Little Sue Creations Inc.6392 Livro Transport Inc.6392 Logis (Québec) inc.6392 Lotissement Québec ltée.6393 Luso Sporting of Montreal Inc.6393 Luxor Construction Inc.6393 M.B.Monuments Ltd.6393 M.N.L.F.inc.6393 Machinerie St-Maurice inc.6393 Machinerie Tousignant inc.6393 Machineries Lema ltée (Les).6393 Maclar Corp.6393 Maison Mademoiselle de Paris ltée (La).6393 Maisons Modulaires inc.6393 Manseau Milling Ltd.6393 Mansville Uranium Ltd.6393 Maple Cleaning Center Inc.6393 Marché-escompte de Québec inc.6393 Marotte transport inc.6393 Mercerie Paul-Aimé ltée.6393 Merit Furs Inc.6393 Meubles B.D.(69) inc.(Les).6393 Meubles Bellehumeur ltée.6393 Meuniers suprêmes limitée (Les).6393 Milaum Investments Inc.6393 Mirad inc.6393 Modes Donali inc.(Les).6393 Mont Ste-Adèle Lodge Inc.: \u2022 \u2022 ¦ 6393 Montage productions inc.6393 Montreal Commercial Foreign Trade Company Ltd.6393 Municipal Mortgage Corporation Ltd.6393 Nesger Investment Inc.6393 980 St-Antoine Ltd.6393 Noark Holdings Ltd.6393 Norcanda Québec Limited.6393 Nordex Development Ltd.6393 Norgrev Construction Ltd.6393 O'Malley Brewery Ltd.6393 O'Neil Paints Inc.6393 Oeuvre des terrains de jeux de l'Assomption (L-).6393 Olive Electro Dynamics Inc.6393 Olympia Aluminum Mfg Ltd.6393 P.A.R.transport inc.6394 P.-M.Packers Limited.6394 Papeterie St-Laurent inc.6394 Paradis (O.) inc.6394 Patenaude (L.) auto centre inc.6394 Perma-roc inc.6394 Phoebus Imports Inc.6394 Placements Lyon ltée (Les).6394 Placements Tracv inc.(Les).6394 Poirier (J.A.) Limitée.6394 Ponçages industriels inc.(Les).6394 Posteritex inc.6394 Pratte & Company Limited.6394 Precision Steel Rule Dies Ltd.6394 Preville Associates Inc.6394 Productions Da Sylva inc.(Les).6394 Productions Hyd inc.(Les).6394 Productions Mojack inc.(Les).6394 Produits laitiers inter-provinciaux ltée (Les).6394 Produits Tino inc.(Les).6394 Promotions de travail de Montréal ltée.6394 Québec Forged Products Ltd.6394 Queen's Hotel (Montreal) Limited.6394 R.P.M.garage inc.6394 R;Q.Builders Inc.6394 Raspberry Mahogany Shops Inc.6394 Reisler & Weisbord Inc.6394 Rela Construction Co.Ltd.6394 Réseau électrique Potvin ltée (Le).6394 Restaurant Le Campeur inc.6394 Restaurant Le Florence inc.6394 Restaurant Le Nocturne inc.6394 Restaurant Lehoux inc.6394 Restaurant Mambo inc.6394 Richelieu Woodworking Ltd.6395 Rigaud fonderie ltée.6395 Robitaille Electric Corporation.6395 Rofdub Investments Inc.6395 Roi-Art Sales Co.6395 S.A.U.S.Inc.6395 St Louis Rancho inc.6395 St Martin Development Corp.6395 Ste Thérèse Investment Corp.6395 Salem Exploration Limited.6395 Salon Pierre Daoust inc.6395 Scharf Painting & Decorating Contractors Ltd.6395 Screen Process Sales Co.6395 Seagull Prk Co.Ltd.6395 Seawood Investment Corp.6395 Securibec Inc.6395 Service Esco ltée.6395 Servoparc inc.6395 6550 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1973, Vol.105, So.U Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Sherbrooke Steak House Inc.6395 Sijan construction inc.6395 Silcan Nlines Ltd.6395 Société de criminologie du Québec.6395 Société G.B.R.inc.(La).6395 Société immobilière L.L.G.inc.6395 Société Nucletron inc.6395 Socicx Inc.6395 Socrates School Uns Service Ltd.6395 Solibec Inc.6395 Sorelois ltée (Le).6395 Southern Holdings Cor|>oration.6395 Southgate Graphics Ltd- 6395 Spruccwood Fish & Game Club .6395 Stamp Mart Inc.(The).6395 Stanwood Precision Corp.6395 Stelat Investments Inc.6395 Studio d'amaigrissement forme miracle île Trois-Rivières inc.6395 Studio 437 inc.6395 Sunnyside Properties Inc.6395 Sunset Sportswear Inc.6396 Suscon Corporation 6396 Syndicat des consommateurs du guide italien inc.6396 T.& T.Cleaners Inc.6396 Tapis Longueuil inc.6396 Tardif (Jean-Marc) inc.6396 Tcmpleton Development Corporation.6396 Terko Investment Corp.6396 Théâtre des Prairies.6396 Theâtrix (Le).6396 Thermo-Pan Inc.6396 Thruway auto centre inc.6396 Trapper Québec Inc.6396 Twin Pinnacle Towers Corp.6396 Troy Investments Ltd.6396 Unity Land & Housing Ltd.6396 Universal Concrete Services Ltd.6396 Vendette (Raymond) ltée.6396 Ville Emard Packaging Companv Ltd.6396 X-L Screw Mfg Co.Ltd.6396 Zacharie (Antoine) limitée.6396 Zeco Ltd.6396 Zillmann (A & G) inc.6396 Zlata Praha Club Inc.6396 Westmount Business Services Inc.6396 Willi eh Realty Co.Ltd.6396 Worldwide Holiday Club Inc.6396 Revocation de dissolution: Rerocalion of Dissolution: Ross (E.R.) Inc.650s Société coopérative agricole Cooperative Agricultural Association Société coopérative agricole de Ste-Hedwidge (Dissolution).6501 Société d'habitation Québec Housing du Québec Corporation Municipal Housing Bureau of Ormstown (L.Pl).6495 Office Municipal d'Habitation d'Ormstown (L.P.).6495 SOUMISSIONS TENDERS demandes de Requests for Bois-des-Filion.village.6515 Donnaconna.ville-town.6519 Nicolet ville-town.6517 Provencher, c.s.r.-r.s.b.6513 Saint-Michel-d'Yamaska.par.6512 SYNDICATS PROFESSIONAL PROFESS ION N ELS S YNDICA TES Association des professeurs de Mont-Royal (Const.-Inc.).;.6508 Syndicat des métiers de la construction de \"Charlevoix Est inc.(C.S.D.) (Nom-Name eh.).6509 VENTES SALES Effets non réclamés Unclaimed Goods Canadian National Railway Company.6521 Cl'Express Limited.6521 Cie des Messageries CP limitée (La).6521 Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada.6521 Par Shérifs By Sheriffs Beauharnois Beauharnois Lafleur rs Fortier.6526 Gaspé Gaspé Bisson vs Bisson.6527 Caisse populaire de Hâvre-aux-Maisons (La) vs Paratte.6527 Mégantic Mégantic Caisse populaire d'Invcrness vs Champagne 6528 Montréal Montreal Bank of Nova Scotia (The) M Tremblay.6530 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Le Curateur Public et al.6529 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) rs Toreno Homes Inc.et al.6528 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Renato Construction Limited et al.6531 Banque de la Nouvelle Ecosse (La) vs Tremblay.6530 Caisse Populaire St-Grégoire Le Grand (La) vs Bishara.6532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1973, 105' année, n° U 6551 Montréal Montreal (suite) (continued) Montreal City and district Savings Bank (The) vs Toreno Homes Inc.el al.6528 Montreal City and district Savings Bank (The) vs Renato Construction Limited et al.6531 Montreal City and district Savings Bank (The) vs The Public Curator et al.6529 Pontiac Pontiac Champlain Aluminum Inc.vs Laporte.6532 Taxes Taxes Anjou, ville-city.6441 Gatineau.ville-town.6435 Montréal-Xord-North, cité-city.6450 Pierrefonds.ville-city.6432 St-Léonard, cité-city.6453' SOMMAIRE Assemblée nationale.6526 Associations coopératives, Loi des.6475 Avis divers.6475 Caisses d'épargne et de crédit.6474 Changement de nom, \\jOI du: Demandes.64(59 Commission des transports du Québec 6397-6522 Compagnies, Loi des Abandon de charte.(5467-6533 Changement de nom.6469 Demandes d'abandon de charte.6479 Divers.6483 Fusion.6468 Lettres patentes (/ro partie).6455 lettres patentes (3° partie).6464 Lettres patentes supplémentaires.6465 Sièges sociaux.6485 Compagnies étrangères.Loi des: Agent.6473 Permis.6473-6533 Curatelle publique.6495 Demande à la Législature.6454 Liquidation, Loi de la.6502-6533 Loi électorale du Québec.0510 Ministères: Affaires municipales.0502 îlducation.6500 Institutions financières, compagnies et coopératives : Assurances.6o01 Richesses naturelles.6509 Terres et forêts.6493 Transports.6431 Proclamation.6500 Régie de l'assurance-maladie du Québec 6490 Renseignements sur les compagnies.Loi des: Avis de dissolution éventuelle de corporations.6367 Lettres patentes annulées.6386 Révocation de dissolution.6508 Sociétés coopératives agricoles.6501 SUMMARY Application to Legislature.6454 Change of Name Act: Applications.6469 Companies Act: Amalgamation of companies.0468 Applications for surrender of charter.6479 Change of name.6469 Head offices.6485 letters patent {Part I).6455 Letters patent {Part III).6464 Letters patent supplementary.6465 Miscellaneous.'.6483 Surrender of charter.6467-6533 Companies Information Act: Letters Patent Annulled.6386 Notice of Eventual Dissolution of corporations.6367 Revocation of Dissolution.0508 Cooperative Agricultural Associations.0501 Cooperative Associations Act.6475 Departments: Education.6500 Financial Institutions, Companies and Cooperatives:' Insurance.6501 Lands and Forests.6493 Municipal Affairs.6502 Natural Resources.6509 Transportation.6431 Extra-Provincial Companies Act: Agent.6473 Licenses.6473-6533 Miscellaneous Notices.6475 National Assembly.6526 Proclamation.6500 Professional Syndicates Act.6508 Public Curatorship.0495 Québec Election Act.6510 Québec Health Insurance Board.6496 Quebec Housing Corporation.6495 Québec Transport Commission.6397-6522 Société d'habitation du Québec.6495 Sales: Unclaimed Goods.Soumissions.6512 6521 Syndicats professionnels, Loi des.Ventes : 6508 Effets non réclamés.6521 Par shérifs: Beauharnois.6526 Gaspé.6527 Mégantic.6528 Montréal.6528 Pontiac.6532 Pour taxes 6432 By Sheriffs: Beauharnois.6526 (îaspé 6527 MéganUç.6528 Montreal.6528 Pontiac.6532 FOU taxes.Savings and Credit Ul Tenders.6432 6474 6512 Winding-Up Act.6502-6533 règlements d'application des lois La série complète: $150 Vol.1 : Généralité, Fonction publique.Justice.Vol.2: Affaires culturelles.Finances, Revenu, Richesses naturelles.Vol.3: Terres et forêts.Agriculture.¦* Vol.4, 5 et 6: Travail et main-d'oeuvre.Vol.7: Affaires sociales.Affaires municipales.Tourisme, chasse et pêche.Vol.8: Industrie et commerce.Transport, Communications, Éducation.Vol.9: Corporations professionnelles et Institutions financières.Vol.10: Index alphabétique des titres, des sous-titres, et des paragraphes, des lois et des textes réglementaires.\u2022 10 volumes, reliure à anneaux, couverture rigide, 800 p.chacun.\u2022 Groupent les règlements d'application des lois de tous les ministères.© Édition bilingue.\u2022 Mise à jour périodique (prix à déterminer).\u2022 Complétée par la Partie II Lois et règlements de la Gazette officielle du Québec ($30.par année).Réservez votre série dès maintenant par chèque ou mandat de poste à l'ordre du MINISTRE DES FINANCES et adressé cp/atTp^ïïTTf^ ' ,t | L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC srr\" \"1.Ministère des Communications, Cité parlementaire )É)JA^^' v * Édifice « G » Québec, Canada G1A1G7 S» "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.