Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 2 (no 9)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1974-03-02, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC PARTIE 1 AVIS JURIDIQUES OFFICIAL GAZETTE 2 MARS 1974 N° 9 1631 PART 1 JURIDICAL NOTICES GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1974, 106' année, n° 9 1633 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazelle officielle du Québec.2.La Gazelle officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazelle officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou_tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher 1634 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1971,, Vol.106, No.9 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, 320; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o \u2022 signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRD7TION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20.from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubê, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec.October 25.1972.Pour toute demande renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec GIA 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Quebec GIA 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n\" 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1971,, 106' année, n° 9 1635 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Lettres patentes annulées Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont annulées à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle de ce deuxième avis.Letters Patent Annulled The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow are cancelled from the date of the publication in the Official Gazette of this second notice.Nom de la compagnie Name of the company AGENCE DE COLLECTION INTERPROVINCIALE INC.LES AGENCES C.F.L.LTEE.ALLIANCE DES PROFESSEURS DE DANSE DU QUEBEC INC.APPARTEMENTS 2725 INC.LES APPARTEMENTS PLEIN CIEL LTEE.ARIC LTEE.ARTINO INC.ASSOCIATED METAL PRODUCTS INC.L'ASSOCIATION DES ADULTES DE GRANBY INC.ASSOCIATION DES CLUBS DE SKI DE MONTREAL.ASSOCIATION DES ETUDIANTS (LICENCE) EN SCIENCES DE L'ADMINISTRATION DE LAVAL INC.L'ASSOCIATION DES FEMMES CELIBATAIRES.ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE ST-HYACINTHE INC.ASSOCIATION DES MANUFACTURIERS DE CHAUSSURES DU CHAUVEAU ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES SCOUTS ET LOUVETEAUX LA PROVIDENCE INC.L'ASSOCIATION DES PARENTS DE L'ECOLE NOEL INC.L'ASSOCIATION DES PARENTS DES ETUDIANTS DE CHATEAU-GUAY INC.ASSOCIATION DE PROPRIETAIRES DE PLAGE DES ISLES FABRE-VILLE L'ASSOCIATION DES SOURDS DE VILLE-MARIE INC.L'ASSOCIATION DES TOURISTES ET RESIDENTS DE STE-VERO-NIQUE DE TURGEON AU CROCHET INC.BESTALL INC.BLAIN INC.BOLOCO INC.BONAVENTURE 2102 LTD.Adresse Address Incorporation Date Québec.04 02 1970 Granby.18 06 1964 Montréal.05 03 1969 Montréal.01 05 1969 St-Laurent.06 10 1970 Montréal.17 11 1967 Montréal.19 10 1966 St-Jér6me.05 11 1971 Granby.07 07 1967 Montréal.20 09 1956 Ste-Foy.05 12 1969 Montréal.14 07 1965 Saint-Hyacinthe.18 09 1968 Québec.29 05 1967 La Providence.03 07 1970 Beloeil.20 02 1960 Châteauguay.13 09 1965 Fabreville.28 07 1964 Montréal.17 03 1965 Turgeon.03 11 1966 Montréal.18 12 1968 Pointe-Claire.05 08 1969 Montréal.30 11 1965 Sainte-Foy.11 11 1971 Montreal.22 01 1970 1636 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2.1971, Vol.106, No.9 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date BOUTIQUE ODE INC.BOUTIQUE ORIGINALE LTEE.BOUTIQUE PAPOU INC.BROWNSBURG COMMUNITY RINK ASSOCIATION.C.D.V.HOLDINGS INC.C.G.M.ENTERPRISES LTD.C I R COMBUSTION & SYSTEMS LTD.CM.CLOTHING CONTRACTORS LTD.CP.ASSOCIATES LIMITED.CANADA LAUNDRY LIMITED.CANADIAN PAVILLON FASHIONS 67.CARAVAN CONSTRUCTION (1968) LTD.CENTENNIAL FURNITURE INC.CENTENNIAL PLAZA CORPORATION.CENTRAL FUEL OIL CO.LTD.CENTRE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE DU QUEBEC INC.LE CENTRE DU DESSIN INDUSTRIEL INC.CENTRE DE DISTRIBUTION CHARLEVOIX INC.LE CENTRE DES LOISIRS STE-FAMILLE DE SHERBROOKE.CENTRE MEDICAL DE CHATEAUGUAY LTEE.CENTRE NUDISTE DU QUEBEC INC.CENTRE RECREATIF ET CULTUREL DE ST-BERNARD-SUR-MER INC.CENTRES CULTURELS POPULAIRES LE PATRIOTE INC.CENTRICAST INC.CENTROPARC HOLDING CORPORATION.CEPAR ENTERPRISES LTD.CERAMIC MONTREAL INC.CERBERE FILMS INC.CERCLE SOCIAL ET CULTUREL DES CHIROPRATICIENS.LES CERFS ST-EUGENE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD .CERTIFIED MANUFACTURING CO.OF CANADA INC.CFRC MOTION PICTURES CO.LTD.R.CHABOT CONSTRUCTION INC.CHALET NORMAND MONTREAL INC.CHALET REALTIES CORPORATION.JACQUES CHALIFOUR INC.CHAMBLY HOME OWNERS ASSOCIATION INC.Montréal.19 \" ™° Montréal.« °9 »>™ Montréal.02 09 1971 Brownburg.24 10 1949 Montreal.12 04 1966 Montreal.04 11 1968 Pierrefonds.05 09 1969 Montreal.20 06 1969 Montreal.30 04 1971 Montreal.10 09 1948 Montreal.12 01 1967 Montreal.22 05 1968 Montreal.25 04 1967 Montreal.12 08 1963 Montreal.20 06 1963 Montréal.12 09 1969 Montréal.19 12 1964 La Malbaie.10 09 1969 Sherbrooke.09 11 1961 Châteauguay.10 05 1966 Montréal.19 11 1971 St-Bernard-de-l'Ue-aux- 30 06 1969 Coudres Montréal.15 11 1971 Cap-de-la-Madeleine.04 10 1968 Montreal.08 05 1964 Montreal.31 01 1962 Lery.31 03 1969 Montréal.15 10 1969 Montréal.26 06 1963 Salaberry-de-Valleyfield.23 09 1964 Montreal.20 06 1961 Montreal.06 06 1969 Laval.15 il 1971 Montréal.05 08 1963 Montreal.17 11 1958 Sillery.04 08 1966 Chambly.02 03 1961 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S mars 197A.106' année, n° 9 1637 Nom de la compagnie Name of the company CHAMBLY LOTS INC.CHAMBLY SPORT INC.LA CHAMBRE D'ORIENTATION SOCIALE DE SAINTE-FOY.CHAMDEV CORP.CHAMP LIBRE INC.CHAMPION TIRE CHAINS COMPANY LIMITED.THE CHAMPLAIN GOLF CLUB.CHANTECLERC CONSTRUCTION INC.LES CHANTIERS ETUDIANTS DE QUEBEC INC.LES CHANTIERS DE MONTREAL.LES CHAPITEAUX SPECTACLES DU QUEBEC INC.-.CHAPLEAU PAPIER JOURNAL INC.CHAPMAN, SACKS & ASSOCIATES LTD.CHARCUTERIE LAVAL INC.CHARLEBOIS CONSTRUCTION LTEE.CHARLESTON HOLDINGS CORP.CHARMAC INC.CHARSIL HOLDINGS LTD.CHATEAU FRANÇAIS INC.CHATEAU OLYMPIA INC.CHATEAUGUAY LITTLE LEAGUE INC.CHATEAUGUAY REGIONAL SHOPPING PLAZA INC.CHATON BLEU INC.CHEETAH ENTERPRISES INC.CHEM-KLENZ INC.PAUL CHENARD INC.CHEQUERS CONSTRUCTION & HAULAGE LTD.CHERROD HOLDINGS LTD.CHESTERFIELD REALTIES LTD.CHEVALIERS DE COLOMB DE LA POINTE ST-CHARLES INC.CHEZ FERNAND GIGNAC INC.P.CHICOINE AUTOMOBILES INC.CHICOINE & POULAIN INC.CHICOT LAND LTD.LE CHOCOLAT « LE LAURENTIEN » LTEE.CHOEUR LAURENTIEN INC.CLEARVIEW DEVELOPMENT CORP.Adresse Address Incorporation Date Montréal.26 09 1968 Chambly.20 07 1971 Sainte-Foy.18 12 1967 Jacques-Cartier.21 05 1969 Westmount.14 09 1967 Montreal.19 05 1952 Montreal.04 03 1966 Montreal.05 08 1964 Québec.25 05 1966 Montréal.20 06 1961 Montréal.24 04 1965 Montréal.19 06 1964 Montreal.15 02 1965 Montréal.13 10 1966 Montréal.23 07 1964 Montreal.18 06 1965 Montreal.16 07 1968 Mont-Royal.18 10 1961 Montréal.13 03 1969 Montréal.25 05 1965 Châteauguay.10 08 1966 Montreal.14 12 1959 St-Hippolyte.15 01 1970 Montreal.23 02 1968 Montreal.23 02 1961 St-Hubert.25 04 1969 Montreal.05 12 1960 Montreal.04 06 1959 Montreal.28 07 1969 Montréal.18 12 1963 Duvernay.15 09 1964 Sherbrooke.15 05 1953 St-Hyacinthe.22 08 1961 Montreal.17 03 1959 Montréal.17 05 1968 St-David-de- 15 05 1968 L'Auberivière Montreal.17 03 1959 1638 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March S, 1974, Vol.106, No.9 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Incorporation Address Date Chambly.24 02 1966 Montreal.28 08 1968 Rimouski.21 04 1947 Beauceville.20 09 1963 St-Hyacinthe.- 11 06 1968 Montréal.02 10 1964 Sherbrooke.31 12 1970 La Malbaie.05 08 1964 Cabano.29 05 1958 Maria.06 05 1968 Rivière-du-Moulin.09 07 1946 Cap-de-la-Madeleine.25 04 1968 Montréal.07 12 1970 Aima.12 05 1964 Aylmer.26 09 1964 Québec.28 03 1969 La Tuque.17 05 1961 Saint-Joseph-de- 20 08 1968 Beauce Chicoutimi.24 11 1966 Montréal.11 03 1968 Châteauguay.26 11 1962 Kénogami.29 01 1959 La Tuque.15 06 1954 Châteauguay.30 05 1968 Montréal.09 12 1966 Laval.29 12 1965 Trois-Rivières.30 11 1966 Montréal.01 12 1969 St-Roch-Richelieu.07 02 1959 Montréal.18 01 1968 St-Siméon.14 09 1961 Montreal.16 01 1962 Causapscal.27 05 1970 Montréal.15 05 1961 Montréal.24 07 1969 Montréal.20 10 1966 CLINIQUE MEDICALE DE CHAMBLY INC.CLINTON INTERNATIONAL EXPORT TRADING & DEVELOPMENT CORPORATION CLUB DOLLARD.LE CLUB DOLLARD.CLUB DE HOCKEY GAULOIS INC.LE CLUB DE HOCKEY DE L'ILE JESUS INC.LE CLUB DES LOISIRS PRECIEUX SANG DE L'ESTRIE CLUB MAILLOUX.CLUB NAUTIQUE DE CABANO INC.LE CLUB NAUTIQUE MARINA-MARIA INC.CLUB OLYMPIQUE.CLUB OPTIMISTE DU CAP DE LA MADELEINE INC.CLUB OPTIMISTE ST-MICHEL MONTREAL.CLUB PANAGAMI.CLUB PAULO.CLUB DES PROPRIETAIRES & CHAUFFEURS DE TAXIS DE QUEBEC INC.CLUB RICHELIEU LA TUQUE CLUB SOCIAL DES CEDRES.LE CLUB SOCIAL DE CHICOUTIMI NORD INC.CLUB SOCIAL PACIFIQUE.CLUB DE TIR DE CHATEAUGUAY INC.LE COMITE DES LOISIRS DE STE-CECILE DE KENOGAMI____ LA COMMISSION TOURISTIQUE DE LA MAURICIE INC.COMMUNITY ASSOCIATION OF GREATER CHATEAUGUAY.LA COMPAGNIE DE PLACEMENTS LAVALTRIE.COMPO INC.COMPTOIR DE CHARITE INC.LE COMPTOIR DES CONSOMMATEURS DE MONTREAL LTEE CONFECTION ST-OURS INC.CONFECTIONS MARIE INC.CONSEIL D'ORIENTATION ECONOMIQUE DE ST-SIMEON CHARLEVOIX INC.CONSOLIDATED HOSIERY MILLS INC.LES CONSTRUCTIONS DELCOUR INC.LES CONSTRUCTIONS DE LA FAMILLE LTEE.LES CONSTRUCTIONS PASSY INC.COO PROF LIMITEE. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n° 9 1639 Nom de la compagnie Name of the company COOLEX REFRIGERATION INC.COPY PRINT MONTREAL LTD.LE CORPS DE MAJORETTES LES MARQUISES.C.J.COTNAM & ASSOCIATES LTD.COUREUR DE BOIS LTEE.E.COUREY INC.COURTAGE IMMOBILIER DE SEPT-ILES INC.COURVILLE MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).CRAMTECH INC.CREATIONS BELLE INC.D.C.R.ENTREPRISES INC.D.F.E.CONSTRUCTION INC.L.C.DAIGNEAULT INC.DAMAS.DAVREY CORPORATION.DE MICHELI HAUTE COUTURE LTEE.DEE JAY CORP.DELSON TRAILERS HOME INC.GILBERT DESJARDINS INC.DICAIRE CHEMICAL CO.LTD.DOMAINE DU LAC CHEVREUIL INC.DOMAINE MARIA CHAPDELAINE INC.DROLET & DEMERS INC.DUCHESNE AUTO LOCATION LTEE.E.C.P.I.CONSULTANTS LTD.EASTON CHARGERS FOOTBALL CLUB.EGLISE MISSIONNAIRE DU PLEIN EVANGILE.ELAN ESTHETIQUE INC.CHARLES ELLIOTT CONSTRUCTION INC.L'ENCAN T.V.DES LIONS INC.LES ENTREPRENEURS DE CHEMINS D'HIVER DE L'EST DU QUEBEC ENTREPRISES OUTARDES INC.LES ENTREPRISES B.L.LIMITEE.LES ENTREPRISES CHELRALD INC.LES ENTREPRISES DU LAC CHANTAL INC.LES ENTREPRISES M.G.W.INC.LES ENTREPRISES PALMAC INC.Adresse Address Incorporation Date Montréal.16 02 1970 Montreal.04 11 1968 Forestville.31 12 1971 Montreal.06 11 1963 Montréal.08 07 1966 Lacolle.10 10 1962 Sept-Iles.04 07 1967 Duparquet.25 09 1944 Montréal.30 07 1964 Québec.08 02 1968 Montréal.10 04 1967 Blainville.06 08 1968 Verdun.09 01 1964 Templeton.06 04 1965 Montréal.23 12 1960 Montréal.04 08 1967 Montreal.16 09 1959 Québec.17 05 1967 Montréal.03 02 1969 Montreal.15 12 1965 Montréal.07 12 1967 Repentigny.02 11 1966 Québec.11 11 1966 Aima.06 12 1968 Montreal.13 05 1966 Montreal.07 12 1966 Montréal.02 06 1971 Québec.28 10 1966 Montréal.30 07 1963 Ste-Foy.30 03 1965 Rimouski.30 05 1968 Chute-aux-Outardes.30 04 1968 Cantic.11 06 1963 Montréal.09 02 1967 Pont Viau.30 04 1964 Montréal.18 07 1969 Ste-Geneviève.21 10 1965 lf>40 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2.1974, Vol.106, No.9 Nom de la compagnie Name of the company LES ENTREPRISES PAREXCO LTEE.LES ENTREPRISES PIRIDA INC.ENTREPRISES Y.MONGEON LTEE.ENTRETIEN SMARTEC INC.ERACLEA SHOES INC.EVERGREEN LAND DEVELOPMENT CO.EXCAVATION LERY INC.LES EXCAVATIONS STE-AN AST ASIE INC.EXCEL IMPORT INC.EXCEL PROMOTIONS INC.EXECUTIVE FITNESS CENTRES INC.LES EXPEDITEURS DU QUEBEC INC.EXPERT CONSTRUCTION INC.L'EXPLOITATION AGRICOLE DE SAINTE-SERAPHINE INC.LES EXPORTATIONS FORESTIERES LOSUMA (QUEBEC) LTEE F.D.F.LTEE.FAT PLANIFICATION SECRETARIAT INC.FAIRMOL'NT THEATRE COMPANY.FAIR VIEW HOMES INC.THE FAIRVIEW RESIDENTS ASSOCIATION.LA FAMILLE TRUDEL (LE) INC.LA FAMILLE VOYAGE INC.FANAL DU PORT INC.FANTAISIE DU PRINTEMPS (MURDOCHVILLE) INC.YVES FARAND LTEE.FATA FURNITURE LTD.LEO FAUCHER CONSTRUCTION LTEE.FAYLE COPPERSMITH WORKS LIMITED.LA FEDERATION DES CONSOMMATRICES DU QUEBEC INC.FELDMORS FUR INC.FELMORE INVESTMENT CORP.FERBEC INC.FERBER DEVELOPMENT INC.FERBLANTERIE TROPICALE INC.FERROSTEEL CORPORATION.LE FESTIVAL MARIA CHAPDELEINE INC.FIBRALUM INCORPOREE.Adresse Incorporation Addrett Date Disraeli.11 03 1971 Ste-Anne-des-Monts .12 11 1968 Angers.27 01 1967 Côte Saint-Luc.03 OS 1971 Montreal.14 01 1972 Montreal.26 02 1958 Ste-Philomène.25 11 1964 Sainte-Anastasie-de- 24 12 1969 Nelson Beauhamois.30 03 1965 Jacques-Cartier.04 11 1963 Montreal.23 12 1968 Petite-Rivière-Nord.07 12 1961 Laval.25 08 1966 Victoriaville.06 06 1966 Montréal.14 02 1963 Laval.10 06 1966 Montréal.12 09 1963 Montreal.08 OS 1951 Montreal.27 05 1963 Dollard-des-Ormeaux 03 08 1966 Montréal.06 06 1950 Montréal.20 02 1968 Montréal.29 06 1967 Murdochville.22 02 1965 Dorion.06 03 1959 Montreal.16 06 1966 Cowansville.15 03 1963 Montreal.28 10 1942 Montréal.08 09 1966 Montreal.14 05 1959 Montreal.03 03 1959 Causapscal.09 08 1971 Québec.23 08 1971 Montréal.17 11 1966 Montreal.13 07 1964 Alma.16 03 1964 Laval.02 08 1968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1971, 106' année, n° 9 1641 Nom de la compagnie Name oj the company Adresse Address Incorporation Date LES FIBRES DE VERRE FRONTENAC INC.FIESTA REALTY CORP.FILATEXT INC.FLASH IMPORT EXPORT INC.FONDATION GRANDS PRIX DU DISQUE ET DE LA CHANSON.LE FONDS DE LA CHAMBRE DU COMMERCE DES JEUNES DU DISTRICT DE MONTREAL INC.LE FONDS INDUSTRIEL DE FARNHAM INC.FONTAINBLEAU FABRICS INC.FOYER CURE CONSTANTIN INC.FOYER D'HEBERGEMENT DE ST-FABIEN DE RIMOUSKI.FOYER SAINT VALLIER.FRANCHISE MARKETING CONSULTANTS (MONTREAL) INC.FURCRAFT INC.CHARLES F.GAGNON INC.GA-MO INC.GARAGE FORTUNAT ROY INC.GLENREET INC.THE GLOBE INTERNATIONAL CORP.GLOBELMI INC.GOLD LAND CHIBOUGAMAU MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) RONALD GOLDMAN INC.GRAND APARTMENTS INC.GUE-MAR EXCAVATION LTEE.H.F.D.CORPORATION LTD.H.M.AGENCIES LTD.H.M.SMALL SALES INC.HABITAT VICTORIA VILLE LTEE.R.HEBERT SPECIALTIES INC.HELMA INVESTMENT CORP.HENRI BAR-B-Q INC.HI-DEE MANUFACTURING CORP.HILL TOP INN INC.HOBBIT INC.L'HOPITAL DE CLARKE CITY.HOTEL CHATEAU VENISE INC.HOTEL COLERAINE INC.Saint-Méthode-de-Frontenac Chomedey.Montreal.Montreal.Montréal.Montréal.Farnham.Montreal.St-Jérôme.Saint-Fabien.St-Vallier.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.St-Hubert.Kirkland.Montreal.Laval.Chibougamau.Montreal.Montreal.St-Constant.Montreal.Montreal.Montreal.Victoriaville.Alma.Montreal.LaSarre.Montreal.Vaudreuil.Montreal Clarke City.Venise.Coleraine .21\t05\t1969 28\t04\t1964 11\t01\t1965 m\t08\t1966 11\t04\t1968 24\t11\t1966 Ki\t11\t1961 25\t11\t1964 14\t11\t1969 24\t01\t1969 03\t11\t1969 13\t06\t1969 24\t01\t1939 18\t12\t1963 31\t03\t1969 27\t03\t1969 19\t06\t1969 10\t04\t1959 18\t06\t1968 12\tOS\t1966 30\t08\t1968 02\t03\t1967 21\t03\t1961 01\t08\t1957 15\t01\t1964 15\t02\t1963 04\t01\t1967 01\t10\t1956 14\t10\t1959 OS\t09\t1969 06\t04\t1967 09\t05\t1966 13\t11\t1968 26\t02\t1964 01\t06\t1962 26\t07\t1969 1642 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 2.1974.Vol.106.No.9 Nom de la compagnie Incorporation Name of the company Addrts, Date \t\t04\t06\t1969 \tQuébec.\t23\ta\t1949 \t\t\t09\t1967 \t\t04\t07\t1968 \t\t07\t06\t1954 \t\t\t\t \t\t\t12\t1970 \t\t23\t08\t1968 \t\t\tos\t1968 \t\t26\t09\t1968 \t\t\t19\t1971 INTERNATIONAL CHEMICAL LABORATORIES LTD.\t\t27\tos\t1968 INTERNATIONAL EXPLORATION CORP.(NO PERSONAL\t\t\t02\t1966 LIABILITY)\t\t\t\t \t\t29\t11\t1966 \t\t\t06\t1 w,s \t\t25\t05\t1967 \t\t14\t03\t1969 \tSorel.\t15\t12\t1969 JOHN R.JAMES INC.\t\t20\t06\t1969 JARDINS DE LA CONCORDE LTEE.\tLaval .\t09\t10\t1969 JEUNE CHAMBRE DE CHIBOUGAMAU INC.\t\t21\t04\t1964 LA JEUNE CHAMBRE DE GATINEAU INC.\tGatineau.\t19\tO.i\t1965 \t\t16\t11\t1949 LA JEUNE CHAMBRE DE HOWICK INC.\t\t25\t11\t196f LA JEUNE CHAMBRE DE NOTRE-DAME D'HEBERTVILLE INC.\tNotre-Dame\t09\t08\t1967 \td'Hébert ville\t\t\t LA JEUNE CHAMBRE DE PONT-ROUGE.\tPont-Rouge.\t08\t06\t196( JEUNE CHAMBRE DE RIMOUSKI INC.\tRimouski.\t.24\t11\t196( JEUNE CHAMBRE DE LA RIVE SUD.\t\t31\t03\t196! LA JEUNE CHAMBRE DE SAINT-PASCAL INC.\tSt-Pascal.\t12\tos\t1964 LA JEUNE CHAMBRE DE TROIS-RIVIERES INC.\tTrois-Rivières.\t26\t10\t1933 LA JEUNE CHAMBRE DE VILLEREMY.\tSt-Rémi.\t02\t06\t1967 KEBEC TRUCK CENTER (1969) LTD.\t\t14\t01\t1969 \tMontreal\t06\t09\t1968 KOSCOT DISTRIBUTION CENTRE OF QUEBEC LIMITED.\tMontreal.\t22\t10\t1969 \tMontreal.\t16\t06\t1964 \t\t\t04\t1956 \tCharlesbourg.\t19\t11\t1969 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1971, 106' année, n° 9 1643 Nom de la compagnie Name of the company LABORATOIRES L.G.S.LTEE.LACHINE AUTO CENTER LTD.LAURENT ELECTRIQUE LTEE.LAVAGE D'AUTO CHAYER INC.LAVAL METALS & SMELTING INC.LAVAL WOODWORK INC.LAV-MOBILE INC.THE LAY WHIP COMPANY LIMITED.LEBOUR INCORPOREE.LECLERC & FILS LIMITEE.LEFORT T.V.INC.LEMIEUX & CHENE AUTO LTEE.LEO FISH & CHIPS LTEE.LIBRAIRIE SOLIS (LONGUEUIL) INC.LIGUE DES CITOYENS DTBERVILLE INC.LA LIGUE DES CITOYENS DE NOTRE-DAME-DE-LORETTE DU COMTE DE CHAUVEAU INC.LA LIGUE DE CROSSE DU QUEBEC LTEE.LA LIGUE DE HOCKEY MINEUR DE ST-JEAN-DTBERVILLE INC.LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE ST-FELICIEN.LOCATION CHAMPLAIN INC.LOISIRS SAINT-FERDINAND DE FABREVILLE INC.LES LOISIRS DE STE-PERPETUE (LTSLET).BEVERLEY LUN INC.M.F.PLUMBING & HEATING SUPPLY CONTRACTING LTD.MAGASIN LAVAL.MAIN GARMENT CENTER INC.MAISON MOBILE L.G.LTEE.LES MAITRES CHARCUTIERS DE MONTREAL LTEE.MAJORETTES COLIBRIS DE LACHUTE INC.MARILENA PIZZERIA TOC.MARION AUTOMOBILES LTEE.MARKO HOLDINGS CORPORATION.MARLEAU & FRERE LIMITEE.MARLEEN PRODUCTS (CANADA) LIMITED.MARLIA INVESTMENTS LTD.MARMUR INVESTMENTS LTD.MAROU INC.Adresse Address Incorporation Date Montréal.\t30\t11\t1966 \t20\t08\t1959 Sept-Ues.\t26\t03\t1969 \tOS\t02\t1959 Laval.\t08\t07\t1969 \t08\t11\t1968 \t01\t08\t1968 \t19\t11\t1912 Charlesbourg.\t14\t11\t1966 Salaberry-de-Valleyfield.\t21\t10\t1963 \t22\t07\t1968 \t30\t03\t1966 \t28\t07\t1964 Longueuil.\t06\t10\t1970 Iberville.\t24\t02\t1966 Notre-Dame-de-Lorette.\t26\t09\t1966 St-Pierre.\t21\t12\t1964 St-Jean.\t01\t02\t1966 St-Félicien.\t08\t06\t1950 Québec.\t18\t08\t1966 Fabreville.\t10\t03\t1965 Ste-Perpétue.\t14\t04\t1966 Laval.\t24\t11\t1969 \t24\t07\t1968 \t26\t08\t1958 \t23\t10\t1962 Desbiens.\t16\t05\t1969 Montréal.\t22\t06\t1970 Lachute.\t05\t04\t1967 Laval.\t15\t01\t1969 \t01\t12\t1958 Montreal.\t25\t10\t1950 Chomedey.\t12\t03\t1965 \t29\t00\t1964 \t02\t12\t1963 Montreal.\t23\t12\t1958 Ste-Agathe-des-Monts.\t13\t08\t1970 1644 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1971, Vol.106, No.9 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Incorporation Address Date Montreal.06 05 1960 Montreal.23 01 1970 Chicoutimi.23 04 1970 Montreal.03 01 1969 Montreal.14 01 1956 Magog.09 01 1961 Montréal.06 03 1967 Montréal.11 12 1968 Montréal.28 10 1968 Laval.28 01 1970 Montreal.05 03 1963 Montreal.28 07 1960 Kingsmere.04 03 1947 St-Laurent.19 01 1970 Dorval.23 06 1966 St-Léonard.19 12 1969 Montréal.21 09 1966 Sillery.05 12 1968 Montréal.05 12 1969 Montréal.05 09 1969 Montreal.17 10 1968 Montreal.30 01 1967 Montreal.26 09 1969 Shawbridge.06 08 1969 Châteauguay.13 04 1970 Chicoutimi.23 10 1958 Montreal.25 10 1962 Ste-Marguerite 12 08 1969 Station Granby.15 04 1970 Montreal.03 06 1969 Montreal.28 10 1969 Montreal.23 09 1971 Montreal.09 09 1971 West mount.06 11 1969 Montréal.16 12 1964 Hull.19 09 1963 Montreal.20 02 1969 MARQUETTE SCRAP LTD.G.MARSHALL SIEV INC.MARTER INC.THE MASK INC.MCKENZIE CHIBOUGAMAU MINES LTD.F.H.MEEHAN LIMITED.MILLER INDUSTRIES INC.LA MINE T.L.G.LTEE.MIRLOU INC.MIRROR OF TOMORROW ELECTROLYSIS INC.MONTREAL LENDERS EXCHANGE.MONTREAL-NORTH (BEARS) FOOTBALL CLUB .MOUNTAIN LODGE COMPANY LIMITED.MOYER STAINLESS AND ALLOY CO.LTD.MR HOME IMPROVEMENT LTD.G.MUCCI & TREVISONNO LANDSCAPING LTD.MULTISPEC INC.NETTOYAGE YOLAINE INC.NETTOYEUR LEDUC INC.NETTOYEURS OKA INC.THE NEW CHEETAR CLUB \"69\" LTD.NOMAR INVESTMENTS INC.NOR-NEL ENTERPRISES INC.LE NOUVEAU PASTEL INC.NOUVELLES DE CHATEAUGUAY INC.L'O.T.J.DE CHICOUTIMI-NORD.ODANAK INC.ODIN HOLDINGS COMPANY LIMITED.OLYMPIC GLASS INC.ORFA SPORTSWEAR MFG.INC.ORIENTAL BAKERY INC.ORTRADE INC.ORVILLE & WILBUR FLY INC.OSKO INVESTMENTS INC.J.H.OSTIGUY INC.OTTER LAKE DEVELOPMENTS LTD.OVERSEAS INVESTORS & DEVELOPERS (MONTREAL) CORP. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mars 1974, 106' année, n° 9 1645 Nom de la compagnie .Vame of the company PACIFIC CONSTRUCTION LTD.PAGODE TOURS INC.PALMERS PLUMBING SUPPLY (QUEBEC) LIMITED.PAPINEAU SANITRONIC INC.LES PANNEAUX-RECLAMES KEBEC INC.PAQUIN AUTO PARTS LIMITED.PARADIS AUTO CENTER INC.PARAGAUD INC.PARATECH INC.PARE AUTOMOBILES LTEE.PARIS SHOE SALON INC.PARK CAR WASH & TIRE SHOP LTD.PARK TOWN PHOTOCOLOR INC.PARKWAY TRANSPORT LIMITED.PARTHENON PASTRY & BAKERY INC.LE PARTI DU RENOUVEAU MUNICIPAL INC.LA PEPINIERE SAGUENAY LTEE.PILE CONSTRUCTION INC.LES PLACEMENTS B.F.P.INC.LES PLACEMENTS DE CHOIX INC.LES PLACEMENTS CONTACT INC.LES PLACEMENTS C.T.Z.LTEE.PLACEMENTS HI-FI LTEE.LES PLACEMENTS JYLY INC.LES PLACEMENTS NOUVEAU PATRIOTE INC.LES PLACEMENTS R.C.INC.PLAN ALIMENTAIRE MARQUITA LTEE.PLAN DE CONGELATION PIERRETTA LTEE.PONTIAC PAINTING AND SANDBLASTING LTD.GASTON POTVTN LTEE.PRESTIGE DE PARIS INC.LES PRODUCTIONS CHADARO INC.PRODUCTIONS CHANTAL RENAUD INC.LES PRODUCTIONS CHARTON INC.LES PRODUCTIONS FERVIL INC.PRODUCTIONS INTERFILMS INC.PROGRESS DISTRIBUTORS INC.Adresse Address Incorporation Date St-Laurent.15 09 1970 Longueuil.03 02 1970 Montreal.01 09 1965 Gatineau.25 10 1965 Montréal.28 04 1965 Châteauguay.13 05 1964 Montreal.02 05 1966 Vimont.24 07 1964 Montréal.15 07 1964 Sept-Iles.04 07 1966 Montreal.26 01 1968 Montreal.13 05 1965 Montreal.12 08 1969 Montreal.31 10 1969 Montreal.12 09 1967 Laval.18 06 1970 Chicoutimi.13 11 1968 Longueuil.12 08 1970 Montréal.19 02 1970 St-Rémi.11 02 1965 Laval.12 06 1968 Montréal.31 12 1971 Montréal.10 12 1957 Montréal.13 12 1967 Boucherville.16 04 1971 Montréal.25 08 1971 Montréal.28 02 1967 Laval.09 04 1969 Montreal.11 11 1971 St-Félix.13 08 1954 Montréal.02 12 1964 Montréal.05 04 1968 Montréal.11 09 1970 St-Laurent.02 02 1971 Montréal.08 01 1970 Montreal.23 02 1970 Montreal.04 03 1970 1646 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.9 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date LES PUBLICATIONS CHARLEROI INC.PUBLICITE DOMINION INC.QUEBEC FAIRWAY IRRIGATION INC.QUEBEC HOBBYCRAFT INC.QUEBEC WHITEPRINT CO.LTD.QUINCAILLERIE FER-RONEX INC.RACZ TAXI CENTER LTD.RADIO HOCHELAGA INC.RAINBOW DYEING INC.RAYCO CONSTRUCTION LIMITED.RELIANCE OVERSEAS CORPORATION (CANADA) LIMITED.REPENTIGNY MARINE INC.RESIDENCES CHAMPLAIN DE MONTREAL INC.RESTAURANT CHATEAU DU QUEBEC INC.RESTAURANT L'EXPLORATEUR CHAMPLAIN INC.VIC 4 JACQUES ROBERVAL INC.PATRICE ROBICHAUD INC.LES ROULOTTES DE CHICOUTIMI LTEE.ROUYN-NORANDA SKI CLUB.ROYAL COPPER LTD.(NO PERSONAL LIABILITY).S & M ENTREPRISES LTEE.ST MAURICE GOLF & COUNTRY CLUB INC.ST REMI DEVELOPMENT CORPORATION.ST ROCH IMPORT LTD.SALAISON METROPOLITAINE INC.SALAISON TURCOTTE INC.SALON DES QUILLES (ST FELICIEN) LTEE.LA SCIE CHAPAIS INC.SERVICE DE CONSULTATION EN TECHNOLOGIE HOSPITALIERE INC SERVICE D'INFORMATIQUE R.L.P.LIMITEE.Québec.12 11 Montréal.26 11 Pointe-Claire.05 01 Montreal.16 01 Montreal.28 10 Laval.02 10 Montreal.12 01 Montréal.14 02 Montreal.16 03 Montreal.09 01 Anjou.03 08 Repentigny.18 07 Verdun.24 05 Drummondville.23 09 Québec.13 05 Roberval.29 11 Québec.03 11 Chicoutimi.11 03 Noranda.09 03 Montreal.07 02 Montréal.04 01 Shawinigan.10 01 Montreal.16 02 Montreal.28 10 Montréal.03 07 Montréal.26 07 St-Félicien.13 08 Thetford-Mines.16 05 Montréal.12 03 1968 1949 1966 1963 1966 1970 1970 1962 1964 1967 1971 1962 1966 1970 1969 1968 1969 1964 1949 1969 1968 1962 1959 1968 1969 1968 1964 1969 1969 SERV-O-PHOTO INC.SILLERY PLAZA LTD.LA SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE SEMBEC INC (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) LA SOCIETE DES FESTIVALS DE MONTREAL.SOCIETE OVILA PAGE INC.\t.26\t02\t1969 \t.21\t04\t1964 \t.17\t08\t1971 \t.05\t04\t1962 \t\t03\t1965 \t\t07\t1955 \t\t08\t1971 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1971, 106' année, n° 9 1647 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date LA SOCIETE PARENT & VACHON INC.LA SOCIETE DE YOGA DU QUEBEC (EVL) LTEE.SOIFFER ENTERPRISES LTD.SOUTH END DEVELOPMENT CORP.SPORTS MARINE INC.SUD-MEDIA CORPORATION LONGUEUIL.SUPER MARINE INC.SYLMAC ENTERPRISES INC.SYL-MAR INC.TELRAM ENTERPRISES LTD.LE THEATRE DE LA PLACE VILLE-MARIE INC.TOMLEM INVESTMENTS INC.TOURNOI REGIONAL DE HOCKEY PEE WEE SAGUENAY-LAC-ST-JEAN INC.TRADADO INTERNATIONAL COMPANY OF AMERICA (IMPORTS-EXPORTS) INC.CF.TRAFF & ASSOCIATES LTD.TRANS CONTINENTAL MEAT PRODUCTS CORP.TRANS WORLD MARKETING COMPANY.TRANSATLANTIC FILMS COMPANY.TROIS RIVIERES MARINE LTEE.TROPICANA CHINESE FOOD INC.ANTONIO TRUDEL LTEE.TWELVE FIFTY FORT HOLDING CORPORATION.UNIGAZ INC.UNIMONT INC.UNIPLAY INC.UNIVERSAL CHEMICAL DESIGNS LTD.URBAN SHOPPING CENTERS LTD.URO-FILM & MACHINERY CORP.UXMAL INC.VAL STEEL INC.VASSILIADIS AND SINGH IMPORT EXPORT CO LTD VELA CORPORATION.VENDOME METAL WORKS INC.VENTRA RESTAURANT INC.VERDUN AUTOMOBILE INC.VERDUN FILM CORPORATION.Ste-Foy.\t.03\t11\t1966 Montréal.\t22\t08\t1969 \t22\t01\t1970 Montreal.\t25\t01\t1955 \t07\t08\t1968 \t\t09\t1968 Montréal.\t08\t03\t1965 Dollard-des-Ormeaux.\t.27\t10\t1969 Montreal.\t04\t08\t1959 \t18\t10\t1971 Montréal.\t06\t05\t1964 \t05\t02\t1969 Alma.\t12\t03\t1965 Montréal.\t05\t(k,\t1968 Montreal.\t11\t03\t1968 Montreal.\t19\t06\t1964 Montreal.\t03\tID\t1969 Montreal.\t14\t03\t1957 \t11\t03\t1969 \t15\t07\t1964 Québec.\t13\t11'\t1952 \t22\t01\t1968 \t04\t10\t1966 \t09\t07\t1968 Montreal.\t28\t06\t1968 \t21\t07\t1971 Montreal.\t26\tOS\t1959 Montreal.\t27\t05\t1968 \t03\t04\t1969 \t10\t10\t1968 \t03\t11\t1969 \t27\t10\t1969 \t08\t09\t1969 Montreal.\t16\t07\t1969 Verdun.\t29\t05\t1969 Verdun.\t14\t02\t1961 1648 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1971, Vol.106, No.9 Nom de la compagnie .Vame of the company VIDEOMEDIA INC.VILLA ST CHARLES INC.VILLAGE HISTORIQUE JACQUES DE CHAMBLY INC.VIVAN STABLE INC.WALKER ENTERPRISES INC.WALTERS ASSOCIATES INC.WELL-MADE CRAVAT MANUFACTURING COMPANY INCORPORATED THE WHITE RIVER EXPLORATION LIMITED (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) WILVAKEN INC.WITT PLUMBING & HEATING LTD.WORLD WIDE PRODUCTIONS INC.YEAMAN PRINTING CO LTD.ZIGZAG BOUTIQUE INC.ZOLBEC INC.Adresse Address Incorporation Date Montréal.26 09 1968 St-Charles.25 09 1968 Montréal.06 11 1961 St-Janvier.10 02 1970 Montreal.20 11 1969 Montreal.11 09 1969 Montreal.05 07 1932 Montreal.01 05 1956 Magog.31 12 1969 Montreal.27 04 1967 Montreal.23 01 1970 Montreal.26 10 1966 Montréal.09 10 1968 Loretteville.30 08 1968 5615S-0 Le directeur du service des compagnies.Pierre Desjardi.ns.56158-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Lettres patentes ( L partie) Letters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions.Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act.he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Nom / Xamc Siège social / Head Office Incorporation Date ADMAIN (DIVISION PLOMBERIE) INC.Montréal.31 01 74 LES AGENCES M.& M.PAGE INC.755, Delongpré, Québec.07 01 74 LES ALARMES DE L'EST INC.312, rue Boulevard Bernard, 07 08 73 EASTERN ALARM INC.Cowansville.LES ALIMENTS BIGRAS INC.2980, rue Bélanger est, Montréal.21 01 74 MARIE ALLAIRE INC.6944, 9e Avenue, suite 2, Montréal.07 01 74 ALTEC INC.10200, boulevard St-Laurent, Montréal 04 12 73 AMEUBLEMENT R.H.DE JOLIETTE INC.380, Marsolais, Joliette.21 01 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mars 1974.106' année, n° 9 1649 Nom / A'ame Siège social / Head Office Incorporation Date AMIBUS INC.ARSENAULT & COM EAU INC.ASSURANCE-VIE JACQUES THIVIERGE INC.AUDIO ASSOCIES (QUEBEC) LIMITEE.LES AUTOS DE LOCATION J.G.INC.REJEAN BERTRAND LIMITEE.REJEAN BERTRAND LIMITED BIJOUTERIE WILCON LTEE.WILCON JEWELLERY LTD.BOITE A CHANSON LE VIEUX DAMASE INC.BORDELEAU & ASSOCIES INC.BORDELEAU , No.9 Avis de correction (Lettres patentes) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a autorisé la correction des lettres patentes des corporations ou compagnies suivantes: Nom/ F 56158-0 FOYER SUTTON Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement public sous le nom de « FOYER SUTTON ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE D'ACCUEIL ».Le siège social de l'établissement est à Sutton, district judiciaire de Bedford.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.56158-0 SS: 6-74 CENTRE D'ACCUEIL D'ACTON VALE Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement public sous le nom de « CENTRE D'ACCUELL D'ACTON VALE ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE D'ACCUEIL ».Le siège social de l'établissement est à Acton Vale, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.William Tetley.56158-0 SS: 8-74 Notice of correction (Letters patent) The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has authorized the correction of the letters patent issued to the following companies or corporations: FOYER SUTTON The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services, Statutes of 1971, Chapter 48, he has issued letters patent constituting a public establishment under the name of \"FOYER SUTTON\".Said public establishment shall be classified as a \"RECEPTION CENTRE\".The head office of the establishment is in Sutton Judicial District of Bedford.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.56158 SS: 6-74 CENTRE D'ACCUEIL D'ACTON VALE The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services.Statutes of 1971, Chapter 48, he has issued letters patent constituting a public establishment under the name of \"CENTRE D'ACCUEIL D'ACTON VALE\".Said public establishment shall be classified as a \"RECEPTION CENTRE\".The head office of the establishment is in Acton Vale, Judicial District of St.Hyacinthe.William Tetley, Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.56158 SS: 8-74 Vame Siège social Head office Incorporation Date Modification Corrections VTCO (THETFORD MINES) INC.350, boul.Smith sud, Thetford Mines.07 12 73 Remplaçant le nom / Replacing the name: FERNATCO (THETFORD MINES INC.par I by FERMATCO (THETFORD MINES) INC.Le directeur du service des compagnies.Pierre Desjardins.56158-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Services de santé et services sociaux \u2014 Loi sur Health Services and Social Services \u2014 Act on GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1971, 106' année, n° 9 1663 Commission des transports du Québec Québec Transport Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission « proprio motn » (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées.i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014Not otice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.LI \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.3.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). 10T.4 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 2, 1974, Vol.106, No.9 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014¦ transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) vérification de permis annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.* permis spéciaux.Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.(c) (d) (e) ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).Verification of permits.Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.* Special permits.In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu » : I \u2014 Notice \" proprio motu \" by the Commission La Commission donne avis qu'elle entend décider de l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication: The Commission gives notice of its intention to decide on the following proceedings in conformity with the provision of section 2.24 of Regulation 2.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date cf this publication.Rôle M-1155 1948-A (P.l.) UNCLE HARRY'S BUS SERVICE INC., 6060 St.James Street West.Montreal, P.Q.Rôle M-1156 2455-A (P.l.) AUTOBUS MILLE-ÎLES 11967) INC., 805, boul.Munck, Ville de Laval, P.Que.Requérant / Applicant.ALLAIRE, L'HEUREUX, GRATTON & BLAIN, Me Jean Allaire, C.R., 1155, ouest, boul.Dodchester, Montréal, P.Que.Procureur / Attorney.Rôle M-l 157 M D-6-TF BT-1 BUREAU DES TARIFS DU QUÉBEC INC., Edifice Girardin, Suite 400, 1259, rue Berri, Montréal, P.Que.Rôle M-l 158 19463-V-P-l M.ROLLAND DULUDE, 50, rue Vanier, St-Jean, Cté St-Jean, P.Que.Rôle M-l 159 15601-V P-l DURHAM TRANSPORT LIMITED, Percy Street, Colborne, Ontario.Aux fins suivantes: 1) que la décision soit annulée vu le désistement de la part de la requérante.Aux fins suivantes: a) Remplacer dans la décision du 20 décembre 1973 à l'item « restriction » pour voyage à charte-partie le nom de « Ste-Thé-rèse par le nom de Ste-Thérèse Ouest.» Aux fins de disposer du cautionnement à l'occasion de la décision MCR-639-TF rendue par la Commission des transports du Québec en faveur du Bureau des Tarifs du Québec Inc., le 7 janvier 1974.Aux fins de corriger la décision rendue le 1er novembre 1973, en enlevant les mots « en vrac » dans ladite décision.Relativement à la confiscation du cautionnement dans l'affaire suivante: Décision No MS-85 datée du 12 septembre 1973 par laquelle la demande pour permis spécial fut rejetée sans décret de confiscation ou de remboursement de cautionnement accompagnant ladite requête (RE: Reçu No 09631).For the purpose of: (1) cancelling the decision owing to the withdrawal of the applicant.For the purpose of: (a) Replacing in the decision dated December 20, 1973, in the item \"restriction\" for chartered trips, the name \"Ste.Thérèse, by Ste.Thérèse-West.\" For the purpose of disposing of the deposit as a result of the decision MCR-639-TF rendered by the Québec Transport Commission on January 7, 1974, in favour of the Québec Tariff Bureau Inc.For the purpose of correcting the decision rendered on November 1, 1973, by deleting the words \"in bulk\" from said decision.With regard to the confiscation of the deposit in the following matter: Decision No.MS-85 dated September 12, 1973, whereby the application for a special permit was rejected without any order of confiscation or reimbursement of the deposit sent with said request (RE: receipt No.09631). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1971, 106' année, n° 9 1665 Rôle M-l 160 23321-V P-l GEORGE A.LEWIS LTD., 7, Birchwood Court, St-Stephen, New Brunswick.Rôle M-l 161 22845-V P-l JEAN-LOUIS FAFARD TRANSPORT ENRG., (Nicole Page opérant sous le nom de:) 99 Charles-Lemoyne, App.306-B, Longueuil, Que.Rôle M-l 162 598 & 599 P-l BROWN, JACK, No 23350-V, CP.7.Hillcrest Road, Readington, New Jersey.U.S.A., voiturier-renorqueur et M.G.M.TRANSPORT CORPORATION, No 22940-V, 70, Maltese Drive.Tokowa.New Jersey, 07512.U.S.A.voiturier-roulier.Rôle M-l 163 22326-V 14043-V D-1C G.NADEAU TRANSPORT ENRG., (Guy Nadeau) 970, Goyer, St-Bruno de Montarville, Cté Chambly, Requérant / Applicant et / and RAPID TRANSPORT TERMINAL LTD., 8577, Boul.Pascal Gagnon.Montréal 458, P.Q.intimée / defendant.Rôle Q-0785 189-A-P-l TF AUTOBUS LAVAL LIMITÉE, 372 Avenue Ste-Brigitte, Ste-Brigitte de Laval, Cté Montmorency, P.Q.En vue de corriger la décision de la Commission rendue en date du 19 décembre 1973 dans laquelle le numéro de permis apparaît comme étant 23221-V alors qu'il devrait être No 23321-V.Relativement à la remise ou à la confiscation du cautionnement déposé par l'opposante (Transport d'Anjou Inc.15-V) par l'entremise de son procureur: Guertin.Gagnon & Lafleur, Avocats: dans l'affaire suivante: Décision No MS-376 datée du 29 novembre 1973 par laquelle un permis spécial était octroyé au requérant sans qu'une décision ne soit prise relativement au décret de confiscation du cautionnement de l'opposante (Transport d'Anjou Inc.: 15-V) qui accompagnait ladite requête.Le reçu de l'opposante portait le No 20510.Pour reviser sa décision datée du 12 décembre 1973, en vue de corriger le nom du voiturier-roulier y apparaissant sous la dénomination de: M.G.M.TRANSPORT COMMISSION 1) sur la page frontispice 2) au paragraphe 4 de la page 2; Remplacer ce nom par: M.G.M.transport corporation Convocation.Pour la vérification des services de transport fournis par: Rapid Transport Terminal Ltd., 8577, boul.Pascal Gagnon, Montréal 458, P.Québec, à la demande de la partie requérante.Aux fins de corriger, à la page 3 de sa décision QPV-213 TF du 24 janvier 1974, la fixation de taux faite, soit: dix (10) passages pour $1.00 pour se lire dix (10) passages pour $2.00.For the purpose of correcting the decision of the Commission rendered on December 19.1973, in which the permit number stated is 23221-V, whereas it should be: No.23321-V.With regard to the release or confiscation of the deposit filed by the opponent (Transport d'Anjou Inc.15-V) by its attorney: Guertin, Gagnon & Lafleur, lawyers; in the following matter: Decision No.MS-376, dated November 29, 1973, by which a special permit was granted to the applicant without a decision being rendered respecting the order of confiscation of the deposit made by the opponent (Transport d'Anjou: 15-V) which was attached to said request.The opponent's receipt was numbered 20510.For the purpose of revising its decision dated December 12, 1973, in order to correct the name of the carrier appearing therein as: M.G.M.TRANSPORT COMMISSION.(1) on the front page; (2) in paragraph 4 of page 2; Said name to be replaced by M.G.M.: Transport Corporation.Summons.For the verification of the transport services provided by: Rapid Transport Terminal Ltd., 8577 Pascal Gagnon Boulevard, Montreal 458, P.Québec, at the request of the applicant.For the purpose of correcting, the fixation of rates appearing on page 3 of its decision QPV-213 TF, dated January 24, 1974, that is: ten (10) tickets for $1.00, to read: ten (10) tickets for $2.00.56160-0 I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu ¦ : Rôle M-l 212 P-l Avis « proprio motu » d'audiences publiques de la Commission des transports du Québec concernant les permis de transport à être émis pour desservir le territoire de la Baie James.La Commission, conformément aux dispositions des articles 2.24 et 2.26 du Règlement No 2, donne avis I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission: RollM-1212 P-l Notice \"proprio motu\" of public bearings of the Québec Transport Commission respecting transportation permits to be issued to serve the James Bay territory.The Commission, in conformity with the provisions of sections 2.24 and 2.26 of Regulation No.2, gives 1666 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, MA, Vol.106, No.9 qu'elle instruira en même temps et décidera par la suite toutes les affaires introduites devant la Commission concernant les demandes de permis pour desservir le territoire de la Baie James et qu'à cette fin elle tiendra des audiences publiques où seront entendues toutes les parties intéressées relativement à toutes les demandes actuellement pendantes ou en état d'être entendues.La Commission se propose, au cours de ces audiences, de prolonger s'il y a lieu, certains permis expérimentaux et ce, jusqu'à décision finale sur l'ensemble des demandes et elle se propose également de prolonger, s'il y a lieu, ou de délivrer, si nécessaire, des permis spéciaux dans les dossiers qui seront alors sous considération ou en état d'être considérés.La Commission se propose également de reviser ou de révoquer, pour cause, si besoin était, toute décision antérieurement rendue concernant ce territoire.En conséquence, avis est par les présentes donné de l'intention de la Commission de procéder ainsi à des audiences publiques devant se tenir à Montréal, aux bureaux de la Commission, salle d'audience No 1, 800 est.boulevard de Maisonneuve, 7e étage, le 16 avril 1974, à dix heures et devant se continuer à Montréal les 17, 18, 19 avril et ensuite à Québec, au siège social de la Commission, 585 est, boulevard Charest, 8e étage, les 23, 24 et 25 avril et enfin les 29 et 30 avril à Val d'Or.Rôle M-1247 P-l Avis « proprio motu » d'audiences publiques de la Commission des transports du Québec concernant les permis de transport de ferroutage (Piggyback) à être émis pour Lacolle et Valleyfield.La Commission, conformément aux dispositions des articles 2.24 et 2.26 du Règlement 2, donne avis qu'elle instruira en même temps et décidera par la suite toutes les affaires introduites devant la Commission concernant les demandes de permis de ferroutage (Piggyback) à I-acolle et Valleyfield et qu'à cette fin elle tiendra des audiences publiques où seront entendues toutes les parties intéressées relativement à toutes les demandes actuellement pendantes ou en état d'être entendues.La Commission se propose, au cours de ces audiences, de prolonger, s'il y a lieu, certains permis expérimentaux et ce, jusqu'à décision finale sur l'ensemble des demandes et elle se propose également de prolonger, s'il y a lieu, ou de délivrer, si nécessaire, des permis spéciaux dans des dossiers qui seront alors sous considération ou en état d'être considérés.La Commission se propose également de réviser ou de révoquer, pour cause, si besoin était, toute décision antérieurement rendue concernant ce territoire.En conséquence, avis est par les présentes donné de l'intention de la Commission de procéder ainsi à des audiences publiques devant se tenir à Montréal, aux bureaux de la Commission, salle d'audience no 1, 880 est, boulevard de Maisonneuve, 7e étage, le 7 mai 1974, à dix heurse, et devant se continuer les 8, 9 et 10 mai.56160-o notice that it will be hearing concurrently, and will thereafter render a decision thereon, all matters .ntro-duced before the Commission with regard to applications for permits to serve the James Bay territory and that it will hold public hearings for this purpose, during which all interested parties will be heard with regard to all applications presently pending or ready for hearing.The Commission intends, during these hearings, to extend certain experimental permits if need be, the foregoing pending final decision on the aggregate applications, and it also intends to extend, or to issue, as the case may be, special permits in matters which will then be under examination or ready for examination.The Commission also intends to revise or to revoke, for just cause and if need be, any decision previously rendered with regard to this territory.Consequently, notice is hereby given that the Commission intends to proceed with public hearings to be held in Montreal, at the offices of the Commission, Courtroom No.1, 800 De Maisonneuve Boulevard East, 7th Floor, on April 16,1974, at ten o'clock, and to be continued in Montrealo nA pril 17, 18, 19 and thereafter in Québec City, at the head office of the Commission.585 Charest Boulevard East, 8th Floor, on April 23, 24, 25 and lastly on April 29 and 30 in Val d'Or.Roll M-1247 P-l Notice \"proprio motu\" of public hearings of the Québec Transport Commission respecting piggyback transportation permits to be issued for Lacolle and Valleyfield.The Commission, in conformity with the provisions of sections 2.24 and 2.26 of Regulation 2.gives notice that it will he hearing concurrently, and will thereafter render a decision thereon, all matters introduced before the Commission with regard to applications for piggyback permits in Lacolle and Valleyfield, and that it will hold public hearings for this puipose, during which all interested parties will be heard with regard to all applications presently pending of ready for hearing.The Commission intends, during these hearings, to extend certain experimental permits if need be, the foregoing pending final decision on the aggregate of applications and it also intends to extend or to issue, as the case may be, special permits in matters which will then be under examination or ready for examination' The Commission also intends to revise or to revoke, for just cause and if need be, any decision previously rendered with regard to this territory.Consequently, notice is hereby given that the Commission intends to proceed with public hearings to be held in Montreal, at the offices of the Commission, Courtroom No.1,800 De Maisonneuve Boulevard East, 7th Floor, on May 7, 1974, at ten o'clock, and to be continued on May 8, 9 and 10.56160-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1974, 100' année, n° 9 1667 LT \u2014 Avis d'introduction de requêtes : La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.Rôle Q-0728 154-V D-l TF GÉRARD RUEL, St-Odilon, Cté Dorchester, P.Q.Rôle Q-0729 3782-V D-l TF DONAT PARÉ, 272, rue St-Cyrille, St-Raymond.Cté Portneuf, P.Q.Rôle Q-0730 2994-A D-l TF ROBERT GILBERT, 643, 9e Rue Ouest, Thetford Mines, Cté Mégantic, P.Q.Rôle Q-0731 3154-A D-l TF AUTOBUS CÔTÉ ENRG.(Jean-Guy Côté), 4671, boul.de la Baie, Port-Alfred, Cté Chicoutimi, P.Q.Rôle Q-0732 1824-V D-l TF LE DÉMÉNAGEUR QUÉBÉCOIS LTÊE, 1783, Ste-Famille, Ste-Foy, Québec 10, P.Q.Le requérant demande à la Commission des transports une augmentation de ses taux au 100 livres pour le transport d'engrais, moulées ainsi que son tarif à l'heure et son minimum: Taux actuels Present rates II \u2014 Notice of submission of applications : The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.The applicant requests the Transport Commission to increase its rate per 100 lbs for the transportation of fertilizers and feed, and an increase of its rate per hour and its minimum : Taux proposés Proposed rates Entre St-Odilon et Québec / Between St.Odilon and Québec 80.25 100 lbs.Engrais chimique / Fertilisers 80.30 100 lbs.0.25 100 lbs.Moulée I Feed 0.27 100 lbs.3.50 100 lbs.Minimum / Minimum 5.00 100 lbs.6.00 100 lbs.Tarif à l'heure: camion 5 tonnes / Rate per hour: 9.00 100 lbs.6-ton truck 0.20 100 lbs.Moulées: St-Odilon et environs/Feed: St.Odilon 0.22 100 lbs.and vicinity Les autres taux demeurent inchangés.Others rates remain unchanged.Le requérant demande à la Commission des transports une augmentation de ses tarifs de classe entre St-Raymond et Québec ainsi que ses tarif au mille.Les taux proposés sont les suivants: a) 0 lbs.à/to 499 lbs.5) 500 lbs à/fo 999 lbs.c) 1,000 lbs.à/lo 1,999 lbs.d) 2,000 lbs.à/lo 4,999 lbs.e) 5,000 lbs.h/to 9,999 lbs./) 10,000 lbs kjto et plus.Minimum / Minimum.Maison privée / Dwelling house.Classes a et 6 avec tarif à l'heure: Camion de 4 tonnes.810.00 Minimum.10.00 et/ou.0.45 du mille parcouru Le requérant demande une augmentation de tarif pour le transport des employés de Therford Mines aux mines de Bel Asbestos et King Beaver et retour: Taux Taux actuels proposés 83.50 par personne par semaine 84.00 Le requérant demande à la Commission, une augmentation de taux d'une moyenne d'environ 20% pour le transport de passagers par autobus entre Chicoutimi et St-Siméon.Demande d'augmentation de tarif horaire pour déménagement local à Québec: Taux proposés: Camion fourgon Camion et chauffeur.Camion et 2 hommes.Camion et 3 hommes.Camion et 4 hommes.Charge supplémentaire pour fourgon excédant 35 pieds de long.The applicant requests the Transport Commission to increase its class tariffs between St.Raymond and Québec and its tariffs per mile.The proposed rates are the following: Classes 12 3 4 .$1.45 $1.32 $1.18 $1.05 .1.45 1.30 1.16 1.03 .1.38 1.22 1.06 0.93 .1.28 1.00 0.96 0.82 .1.18 1.02 0.88 0.73 .1.10 0.95 0.81 0.68 .4.50 .6.00 Classes a and b with a tariff per hour: A 4 ton truck____ $10.00 Minimum.10.00 and/or.0.45 per mile travelled The applicant requests an increase in tariff for the transportation of employees from Thetford Mines to the mines of Bel Asbestos and King Beaver and return: Present Proposed rate rate $3.50 per person per week.$4.00 The applicant requests from the Commission an increase in rates of an approximate average of 20% for the transportation of passengers, by bus, between Chicoutimi and St.Simeon.Request for an increase in per-hour rate for local furniture-moving in Québec City: Tarif à l'heure $15.00 22.00 29.00 36.00 5.00 Proposed rates: Van Truck and driver.Truck and 2 men.Truck and 3 men.Truck and 4 men Tariff per hour 815.00 22.00 29.00 36.00 Additional charge for a van exceeding 35 feet in length 5.00 1668 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.9 Rôle Q-0733 1501-V D-2 TF ANDRÉ PAQUET, St-Côme.Cté Beauce, P.Q.Rôle Q-0734 769-DY D-l TF DENIS PÉPIN AUTOS LTÉE, 2500, Chemin des Quatre-Bourgeois, Ste-Foy.Québec 10, P.Q.G1V 1W9 Rôle Q-0735 2782-AT D-l TF LES TAXIS DE LUXE ENRG., (Armand Pelletier), 181, boul.Lasalle, Baie-Comeau, Cté Saguenay, P.Q.Rôle Q-0736 23643-V-S-l BERNARD BONNEAU, 957 - 3e Rue, Chibougamau, Cté Abitibi-Est.Demande d'augmentation des taux de classe et d'espèces entre St-Côme (Beauce) et Québec; ainsi que des tarifs horaires et au millage.Pour informations supplémentaires, veuillez consulter les taux à la Commission des transports du Québec.La requérante demande à la Commission des transports une augmentation de tarif pour la location de véhicules de promenade à court terme: Application for an increase in class and commoditv rates between St.Côme (Beauce) and Québec; also an increase in hourly rates and rates per mile.For further information, please consult the rates filed with the Québec Transport Commission.The applicant requests the Québec Transport Commission to increase its tariffs for the leasing of pleasure vehicles on a short-term basis: Taux actuels Present rates $11.95 inc.2.00 33.00 79.50 $13.95 inc.3.00 39.00 89.50 $14.95 inc.3.00 42.00 99.50 $18.95 inc.3.00 54.00 109.50 $ 2.00 $14.00 Taux proposés Économique / Economic Car Proposed rates Par jour / Per day.$11.95 Mille I Mile.inc.Par heure / Per hour.2.00 Fin de semaine / Weekend.33.00 Semaine / Week.79.50 Compact / Compact Car Par jour / Per day.14.95 Mille I Mile.inc.Par heure / Per hour.3.00 Fin de semaine / Weekend.42.00 Semaine/ Week.94.50 Standard / Standard Car Par jour / Per day.$15.95 Mille / Mite.inc.Par heure / Per hour.3.00 Fin de semaine / Weekend.45.00 Semaine/ Week.105.50 Station-wagon / Station-Wagon Par jour / Per day.$18.95 Mille / Mile.inc.Par heure / Per hour.3.00 Fin de semaine / Weekend.54.00 Semaine / Week.119.50 Pleine assurance collision par journée de 24 heures.$ 2.50 Full collision insurance per 24-hour day Pleine assurance collision par semaine.$15.00 Full collision insurance per week Demande d'augmentation de taux pour le service de limousine de Baie-Comeau et Hau-terive à l'aéroport Pointe-Lebel: Taux actuels Tarif régulier Taux proposés $2.00 Baie-Comeau à l'aéroport $4.00 1.50 Hauterive à l'aéroport 3.00 Tarif spécial 87.00 5.00 Baie-Comeau a l'aéroport $10.00 Hauterive à l'aéroport 7.00 Demande de permis spécial.La partie requérante demande le permis spécial suivant: Transport restreint - service local - Chibougamau et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville; Transport restreint - longue distance - territoire - De tous points a tous points situés dans les districts électoraux-provinciaux d'Abitibi-Est et Abitibi-Ouest, à l'exclusion du territoire de la Baie James; Transport restreint - longue distance -rayon - Application for an increase in rates for the limousine service from Baie-Comeau and Hauterive to the airport of Pointe-Lebel: Present Proposed rates rates Regular tariff $2.00 Baie-Comeau to t he airport.$ 4.00 1.50 Hauterive to the ariport 3.00 Special tariff 7.00 Baie-Comeau to the airport.10.00 5.00 Hauterive to the airport.7.00 Application for a special permit.The applicant requests the following special permit: Restricted trucking - local service - Chibougamau and all pointa located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said Town: Restricted trucking - long distance - territory - From any point to any other point located in the Provincial Electoral Districts of Abiti-bi-East and Abitibi-West, except for the James Bay territory; Restricted trucking-long distance-radius - GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1971, 106' année, n° 9 1669 Rôle Q-0737 Q-201883 D-l FLORENT SÉNÉCHAL, 2335, Hubert, Trois-Rivières.Rôle Q-0738 Q-201883 D-2 FLORENT SÉNÉCHAL, 2335, Hubert.Trois-Rivières Rôle Q-0739 Q-200002 MARCEL BRASSARD, 161, rue Dollard, Jonquière, Cté Saguenay, P.Q.Rôle Q-0740 Q-201883 D-3 FLORENT SÉNÉCHAL, 2335, Hubert, Trois-Rivières.Rôle Q-0741 Q-201883 D-4 FLORENT SÉNÉCHAL, 2335, Hubert, Trois-Rivières.Rôle Q-0742 Q-200014 LAURENT LAGACÉ, 84, Le Voilier, Lauzon, P.Q.Rôle Q-0743 Q-201511 D-2 ROSAIRE NEPTON, 156, rue Vauquelin, Jonquière.Rôle Q-0744 3372-A D-2 TRANSPORT SÉCURITAIRE ST-PROSPER INC., St-Prosper, Cté Dorchester, P.Q.Rôle Q-0745 97-A D-6 AUTOBUS DRUMMONDVILLE LTÉE 330, rue Hériot, Dru mmond ville, Cté Drumrnondville, P.Q.De Chibougamau et de tous points situés dans les districts électoraux-provinciaux d'Abitibi-Est et Abitibi-Ouest à ailleurs dans la province, et retour, à l'exclusion du territoire de la Baie James.Dans les trois (3) cas, pour le transport et le remorquage de maisons mobiles et de maisons préfabriquées.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Joseph Dionne portant le No Q-200454 D-2.From Chibougamau and ail points located in the Provincial Electoral Districts of Abiti-bi-East and Abitibi-West to any other point in the Province, and return, except for the James Bay territory.In the three (3) cases, for the transportation and the haulage of mobile homes and prefabricated houses.The applicant requests the Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of Mr.Joseph Dionne bearing No.Q-200454-D-2.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Joseph Dionne portant le No Q-200454 D-3.Le requérant demande h la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Emile Ratté portant le No dossier Q-200003.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faite transférer l'attestation de M.Joseph Dionne portant le No Q-201454 D-l.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Albert Lainesse portant le No Q-200985.Le requérant demande h la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Camille Rousseau portant le No dossier Q-200618.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Willy Desbiens portant le No dossier Q-200701.Modification de l'horaire: Classe de permis: Autobus.Service : Modification de l'horaire, pour ne s'appliquer que le samedi, comme suit: Départ de Scott: 7.30 a.m.au lieu de 6.50; Départ de Québec: 4.15 p.m.au lieu de 5.00 p.m.; Les autres services demeurent aux mêmes heures.Le dimanche, le départ se fait de St-Nar-cisse, St-Bernard, Scott, Ste-Hénédine, St-Isidore, St-Henri, Lévis et Québec.Modification à l'horaire: Classe de permis: Autobus.Service: La partie requérante a déposé à la Commission pour approbation, les nouveaux horaires suivants: The applicant requests the Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of Mr.Joseph Dionne Bearing No.Q-200454 D-3.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of Mr.Emile Ratté bearing file No.Q-200003.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of Mr.Joseph Dionne bearing No.Q-201454 D-l.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of Mr.Albert Lainesse bearing No.Q-200985.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of Mr.Camille Rousseau bearing file No.Q-200618.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of Mr.Willy Desbiens bearing file No.Q-300701.Modification of timetable: Class of permit: Bus.Service: Modification of the timetable, applicable on Saturdays, only as follows: Departure from Scott: 7:30 a.m.instead of 6:50; Departure from Québec: 4:15 p.m.instead of 5:00 p.m.; Other services remain at the same hours.On Sunday the departure takes place from St.Narcisse, St.Bernard, Scott, Ste.Héné-dine, St.Isidore, St.Henri, Levis and Québec.Modification of timetable: Class or permit: Bus.Service: The applicant has filed with the Commission, for approval, the following new-timetables: 1670 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1971, Vol.106, No.9 Role Q-0746 Q-200025 D-8 LÉO MONTAMBAULT.341, St-Maurice.Cap de la Madeleine.Rôle Q-0747 Q-200025 D-9 LÉO MONTAMBAULT, 341, St-Maurice, Cap de la Madeleine.Rôle Q-0748 Q-200025 D-10 LÉO MONTAMBAULT.341, St-Maurice, Cap de la Madeleine.Rôle Q-0749 Q-200025 D-ll LEO MONTAMBAULT, 341, St-Maurice, Cap de la Madeleine, Rôle Q-0750 Q-200025 D-12 LÉO MONTAMBAULT, 341, St-Maurice, Cap de la Madeleine.Rôle Q-0751 Q-200025 D-13 LÉO MONTAMBAULT, 341.St-Maurice, Cap de la Madeleine.Rôle Q-0752 Q-200025 D-14 LEO MONTAMBAULT, 341, St-Maurice, Cap de la Madeleine.Rôle Q-0753 Q-200025 D-15 LEO MONTAMBAULT, 341, St-Maurice, Cap de la Madeleine.Rôle Q-0754 Q-200025 D-16 LEO MONTAMBAULT, 341, St-Maurice, Cap de la Madeleine.1) Les voyages de Nicolet pour Drum-mondville le vendredi 9.15 p.m.et dimanche 9.00 p.m.sont cancellés faute de rentabilité.2) Circuits Drummondville - St-Charles -St-Cyrille - et Drummondville - St-Philippe - St-Nicéphore - qui entreront en vigueur le ou vers le 15 mars 1974.Les principaux changements sur cesdits horaires, concernent les services du matin, de l'après-midi et du soir, qui desservent présentement diverses manufactures de Drummondville et principalement la Celanese.Ces services sont non rentables et c'est pourquoi nous devons diminuer la fréquence entre ces diverses municipalités pour Drummondville.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de \"Taxi Veillette Enrg.» portant le No Q-200185.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de «Taxi Goflin Enrg.» portant le No Q-200186 D-l.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de «Taxi Goain Enrg.» portant le No Q-200186 D-2.Le requérant demande a la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de «Taxi Godin Enrg.» portant le No Q-200186 D-3.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de « Taxi Godin Enrg.» portant le No Q-200186 D-10.I* requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de «Taxi Godin Enrg.» portant le No Q-200186 D-4.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de «Taxi Godin Enrg.» portant le No Q-200186 D-ll.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de « Taxi Godin Enrg.» portant le No Q-200186 D-9.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de «Taxi Godin Enrg.» portant le No Q-200186 D-8.(1) The trips from Nicolet to Drummondville on Friday 9:15 P.M.and Sunday 9:00 P.M.are cancelled owing to their non-profitability.(2) The following routes: Drummondville - St.Charles - St.Cyrille - and Drummondville - St.Philippe - St.Nicéphore, which shall come into force on or about March 15, 1974.The main changes on said timetables pertain to the services given in the morning, in the afternoon and at night, and which presently serve various plants in Drummondville and especially that of Celanese Co.Owing to the fact that these services are not profitable, we must reduce the frequency of our service between Drummondville and these various municipalities.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of \"Taxi Veillette Enrg.\" bearing file No.Q-200185.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of \"Taxi Godin Enrg.\" bearing No.Q-200186 D-l.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of \"Taxi Godin Enrg.\" bearing No.Q-200186 D-2.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of \"Taxi Godin Enrg.\" bearing No.Q-200186 D-3.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of \"Taxi Godin Enrg.\" bearing No.Q-200186 D-10.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of \"Taxi Godin Enrg.\" bearing No.Q-200186 D-4.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of \"Taxi Godin Enrg.\" bearing No.Q-200186 D-ll.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of \"Taxi Godin Enrg.\" bearing No.Q-200186 D-9.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of \"Taxi Godin Enrg.\" bearing No.Q-200186 D-8. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1971,, 106' année, n° 9 1671 Rôle Q-0755 Q-200025 D-17 LÉO MONTAMBAULT, 341, St-Maurice, Cap de la Madeleine.Rôle Q-0756 Q-200025 D-18 LÉO MONTAMBAULT, 341, St-Maurice, Cap de la Madeleine.Rôle Q-0757 Q-200025 D-19 LÉO MONTAMBAULT, 341, St-Maurice.Cap de la Madeleine.Rôle Q-0758 1092-V D-l 11377-V D-l QUÉBEC TRANSPORT INC., 575.rue Arago Ouest, Québec 8.venderesse.et MICHAUD & SIMARD INC., 575, rue Arago Ouest, Québec 8, acquéreur.Rôle Q-0763 17007-V D-l SIGOUIN, ROMÉO, 148 - 12e Avenue, Case Postale 502, Amos (Abitibi).Rôle Q-0764 2986-A D-l TF ANDRÉ DUCLOS, 98, Avenue Royale, St-Tite des Caps, Cté Montmorency, P.Q.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de «Taxi Godin Enrg.» portant le No Q-200186 D-7.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de «Taxi Godin Enrg.» portant le No Q-200186 D-6.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de « Taxi Godin Enrg.» portant le No Q-200186 D-5.Cession de la propriété du système de transport (vente) Québec Transport Inc., demande l'autorisation de céder à Michaud & Simard Inc., 575, rue Arago ouest, Québec 8 No 11377-V la propriété du système de transport suivant: Permis No 1092-V a) Transport général - service local - a) Québec et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite ville.b) Transport général - longue distance -rayon - b) De Québec à tous les endroits situés dans un rayon de trente (30) milles des limites de ladite ville, en suivant les routes principales, et retour.c) Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - c) De Québec à ailleurs dans un rayon de 175 milles et retour, pour le transport de matériaux de construction.Modification de permis.La partie requérante, détentrice du permis de transport suivant: Transport restreint - longue distance -rayon - D'Amos à tous les endroits situés dans les comtés électoraux-provinciaux d'Abitibi-Est et d'Abitibi-Ouest, et retour.Restrictions: 1) Ce permis est restreint au transport de foin, grains, outils et équipement de chantier uniquement aux sites de leur exploitation; 2) Ce permis est restreint à l'usage d'un seul camion dont la capacité ne dépasse pas deux tonnes.Demande d'être autorisée à: \u2014 employer trois (3) camions au lieu d'un \u2014 augmenter la capacité (tonnage) de chacun des camions.Demande d'augmentation de taux pour le transport de personnes entre St-Tite-des-Caps (Village et Chenaux) à St-Lawrence Manufacturing (Giffard): Taux actuels: $1.75 par jour.Taux proposés: $1.90 par jour.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of \"Taxi Godin Enrg.\" bearing No.Q-200186 D-7.The applixant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of \"Taxi Godin Enrg.\" bearing No.Q-200186 D-6.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf the certificate of \"Taxi Godin Enrg.' bearing No.Q-200186 D-5.Transfer of ownership of transportation service (sale).Québec Transport Inc., requests authorization to transfer to Michaud & Simard Inc., 575 Arago Street West, Québec 8.No.11377-V the ownership of the following transportation service: Permit No.1092-V (a) General trucking - local service - (a) Québec and all points located over a distance of not more five (5) miles from the limits of said City.(i) General trucking - long distance -radius - (b) From Québec to all points located within a radius of thirty (30) miles from the limits of said City, along the main highways and return.(c) Restricted trucking - long distance -radius - contract - (c) From Québec to any point within a radius of 175 miles and return, for the transportation of building materials.Modification of permit.The applicant, holder of the following transportation permit: Restricted trucking - long distance - radius - From Amos to all points located in the Provincial Electoral Counties of Abitibi-East and Abitibi-West, and return.Restrictions: (1) This permit shall be restricted to the transportation of hay, grain, tools and logging equipment to the logging operation sites only; (2) This permit shall be restricted to the utilization of a single truck whose capacity does not exceed two tons.The applicant requests authorization to: \u2014 utilize three (3) trucks instead of one (1); \u2014 increase the capacity (tonnage) of each of the trucks.Application for an increase in rates for the transportation of persons between St.Tite-des-Caps (Village and \"Chenaux\" to the plants of St.Lawrence Manufacturing (Giffard) : Present rates: $1.75 per day.Proposed rates: $1.90 per day. 1672 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2.1974, Vol.106, No.9 Rôle Q-0765 3159-A D-l TF SERVICE D'AUTOBUS, DE LA MAURICIE LTÊE.CP.513, Willow.Shawinigan, Cté St-Maurice, P.Q.G9N 6V4 Rôle Q-0766 7138-V D-l TF BEGIN TRANSPORT LTÉE, 208, Iberville est.Rouyn.Cté Témiscamingue, P.Q.Rôle Q-0767 20224-V D-l TF ÉMILLE CHIQUETTE, 792.Laflamme, Chibougamau, Cté Abitibi, P.Q.Rôle Q-076S 22704-V D-3 TF COURRIER TRANS QUÉBEC INC., 2145.rue Lavoisier, Ste-Foy, Québec 10, P.Q.GIN 4B2 Rôle Q-0769 22621-V D-l TF JEAN-MARIE GOSSELIN & FILS LTÉE, 5, Boulevard Plessis, St-Henri, Cté Levis, P.Q.Rôle Q-0770 7466-V D-2 TRANSPORT NATIONAL ENR., (Dame Danielle Garneau Denis), 42^, boul.St-Joseph.Charlesbourg-Ouest, Cté de Québec.Rôle-1115 602-A MURRAY HILL LIMOUSINE SERVICE LTD.1380 Barre Street.Montréal 3, P.Q.La requérante demande à la Commission des transports une augmentation de tarif de l'ordre de 20% pour le transport de voyageurs dans les services inter-urbains de: Trois-Rivières à Grand'Mère et retour.Demande d'augmentation des taux locaux et longue distance ainsi que des taux à contrat pour Acmies Limited et Stewart Machine Works Ltd.Pour informations supplémentaires, veuillez consulter les taux à la Commission des transports du Québec.Le requérant demande a la Commission des transports une augmentation de tarif pour le transport de marchandises pour le compte de la Compagnie de la Baie d'Hudson : Taux actuels: S450.00 par semaine.2 camions l>rt.s du Québec de l'autoriser à donner le** services de location de véhicules en remplacement de la demande du lf> mai 1973 faite sous la raison sociale de Champlain Leasing Ltd.; Service 2 : Leasing of commercial vehicles (trucks, tractors, trailers) and deliver)' vehicles (trucks, tractors, trailers) on a short-term basis (less than one year) for the public at large.Transfer of permit and application for additional right.(1) The applicant vendor requests the Québec Transport Commission to authorize the sale of its services and the transfer of its leasing permits to the applicant purchaser: The shareholders in the applicant vendor company are the following: Fernand Perreault.Pres.2200 common shares J.Denis Lareau, Vice-Pres.1 common share Jacques Filion, Sec.-Treas.1 common share 749 preferred shares Denis Perreault 500 preferred shares Those of the applicant purchaser company are: Fernand Perreault.Pres.98 common shares J.Denis Lareau, Vice-Pres.common share Mrs.Rita Perreault, Sec.-Treas.1 common share (2) The applicant purchaser requests the Québec Transport Commission to authorize it to provide the following additional leasing services: (to be added to those of the transferred permits) : Service 3: Leasing of pleasure vehicles (automobiles and station-wagons) on a short-term basis (less than one year) at 800 Grand Boulevard, Chambly.Service 4: Leasing of commercial and delivery vehicles (trucks, trailers) on a short-term basis (less than one year) at 800 Grand Boulevard, Chambly.Additional right.The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to add the following additional right to its present permit.Service: Short-term leasing of commercial and delivery vehicles within the meaning of the Highway Code from 1401 d'Estimauville St.Québec, P.Q.New application.The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to provide the following vehicle leasing services: Service : Leasing, on a short-term basis (less than one year), of pleasure vehicles (automobiles) within the meaning of the Highway Code, from 130- 1st Avenue, Rougemont, P.Q.Modification.The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to provide the following vehicle-leasing services to replace the application made on May 16.1973 under the name and style of Champlain Leasing Ltd.; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 10G' année, n° 9 1677 LOCATION CHAMPLAIN MONTRÉAL INC., 1,000, boul.Ile-des-Soeurs.Ile-des-Soeurs, Montréal, P.Q.Rôle M-l 135 1086-DYV D.1 CANNONBALL TRUCK RENTALS LEASING LTD.2514 Rosemont Blvd, Montréal 408, P.Q.siège social / Head office, 2399 Royal Windsor Drive, Mississauga, Ontario.Rôle M-l 136 M D-5 TF BT-2 CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS'N., 555 Dixon Road, Rexdale, Ontario, M9W 1H8 Voir liste annexée-requérants faisant partie de The list annexed-members of the Rôle M-l 137 M D-10-TF BT-1 BUREAU DES TARIFS DU QUÉBEC INC.Edifice Girardin, suite 400, 1259, rue Berri, Montréal 132, Que.Membres participants faisant partie du Members participating of Rôle M-l 138 M D-4 TF BT-5 NIAGARA FRONTIER TARIFF BUREAU INC.P.O.Box 184, Buffalo, N.Y.14221.(Membres participants) (Members participating) Service 1 : Location de véhicules de promenade (automobiles et station-wagons) à long terme (un an et plus).Service 2: Location de véhicules de commerce (station-wagons) à long terme (un an et plus).Nouvelle demande.La requérante demande :\\ la Commission des transports du Québec de l'autoriser à donner le service de location de véhicules suivant: Service : Location de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) à long terme (une année et plus) pour le grand public.Tarif No 521 de la Québec-Western Canada Emergency Rate Tariff, B.T.Q.No 3727, Supplément No 8.en ajoutant la compagnie Leamington Transport (Western) Ltd.en tant que participant à l'Ontario-Trans Canada Carrier.Le tarif No 530 de la Québec-Western Canada Emergency Rate, B.T.Q.4041, le supplément No 3.en ajoutant la compagnie Leamington Transport (Western) Ltd., en tant que participant l'Ontario-Trans Canada Carrier.Taux convenus No 22-F, B.T.Q.No 3582.de la Steel Co.of Canada Ltd., taux convenus renouvelés à un niveau supérieur.Taux convenus No 28-A, B.T.Q.No 3616, de la Dominion Foundries and Steel Ltd., taux convenus renouvelés à un niveau supérieur.Demande de modifications de taux.Tarif 6-B: Réductions, annulations, addition.Tarif 70-B: Addition, rectification.Tarif 50-B: Addition, annulation, rectification.Tarif 20: Addition.Tarif 30: Réduction.Tarif 80-A: Addition.Tarif 75: Augmentations, réduction.Suppléments intérims: Augmentations, annulation, addition.Maniwaki-Montréal Transport Ltée No 1884 Note: Pour renseignements supplémentaires, veuillez consulter les demandes déposées à la Commission des transports du Québec.Demande de fixation de tarif: Supplément 29 au Tarif 250-C: (Parties d'automobile).Augmentation de 3%.Supplément 11 au Tarif 261-C: (Marchandise générale).Item 5337 (Addition).Item 6080-C (Addition).Item 9940-A (Réduction).Item 12545 (Addition).Item 14610-A (Augmentation).Supplément 65 au Tarif 270-B; (Tarif de fer et d'acier).Item 2365 (Addition).Supplément 13 au Tarif 368: (Tarif de classe et marchandise).Item 10240-B (Augmentation).Supplément 17 au Tarif 169-A: (Tarif de Taux groupe).Service 1 : Leasing of pleasure vehicles (automobiles and station-wagons) on a long-term basis (one year or more).Service 2 : Leasing of commercial vehicles (station-wagons), on a long -term basis (one year or more).New request.The applicant is asking for the Québec Transport Commission authorization to lease vehicles as follows : Service: Leasing on a long-term basis (one years or more) of commercial and delivery vehicle (trucks, tractors, trailers) for the public in general.Québec-Western Canada Emergency Rate Tariff No.521, T.B.Q.No.3727, Supplement No.8, adding Leamington Transport (Western) Ltd.as participant Ontario-Trans Canada Carrier.Quebec-Western Canada Emergency Rate Tariff No.530, T.B.Q.4041, Supplement No.3, adding Leamington Transport (Western) Ltd.as participant Ontario-Trans Canada Carrier.Agreed Charge No.22-F, T.B.Q.No.3582, Steel Co.of Canada Ltd.renewed Agreed Charge at increased rate level.Agreed Charge No.28-A, T.B.Q.No.3616, Dominion Foundries and Steel Ltd.renewed Agreed Charge at increased rate level.Application for modifications of rates.Tariff 6-B: Reductions, cancellations, addition.Tariff 70-B: Addition, adjustment.Tariff 50-B : Addition, cancellation, adjustment.Tariff 20: Addition.Tariff 30: Reduction.Tariff 80-A: Addition.Tariff 75: Increases, reduction.Interim supplements: Increases, cancellation, addition.Maniwaki-Montreal Transport Ltée.No.1884.Note: For further informations, see application filed with the Québec Transport Commission.Application for Fixation of Tariff: Supplement 29 to Tariff 250-C: (Automobile Parts).Increase of 3%.Supplement 11 to Tariff 261-C: (General Commodities).Item 5337 (Addition).Item 6080-C (Addition).Item 9940-A (Reduction).Item 12545 (Addition).Item 14610-A (Increase).Supplement 65 to Tariff 270-B: (Iron and Steel Tariff).Item 2365 (Addition).Supplement 13 to Tariff 368: (Class and Commodity Tariff).Item 10240-B (Increase).Supplement 17 to Tariff 169-A: (Rate Group Tariff). 1678 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.9 Rôle M-l 139 1948-A-(D.2.) UNCLE HARRY'S BUS SERVICE INC., 6060 St-James Street West.Montreal, P.Q.Rôle M-l 140 22845-V D-l JEAN-LOUIS FAFARD TRANSPORT ENRG., (Nicole Page opérant sous le nom de) (Nicole Page operating under the name of) 99 Charles-Lemoyne, app.306 B.Longueuil, Que.Supplément 30 au Tarif 250-C: (Parties d'automobile).Supplément 12 au Tarif 261-C: (Marchandise générale).Supplément 16 au Tarif 273 et Supplément I au Tarif 273-A.(Pole-Remorque Tarif).Supplément 17 au Tarif 274-C: (Tarif de marchandises en vrac).Supplément 8 au Tarif 290: (Aero Fret).Supplément 14 au Tarif 368: (Tarif de classe et marchandise).Supplément 9 au Tarif 566-B: (Tarif de classe).Supplément 23 au Tarif 630-A: (Tarif de récipient).Supplément 20 au Tarif 777-B: (Tarif de marchandise).Supplément 11 au Tarif GRT-3: (Tarif de taux gouvernement).La requérante demande l'autorisation de donner le service suivant: Classe de permis: Autobus.Service : Transport d'écoliers âgés de trois (3) à sept (7) ans, de leurs domiciles à l'une des écoles suivantes, et letour: Solomon Schechter Academy Inc., 5555, Chemin de la Côte St-Luc, Montréal, P.Q.Hebrew Academy, 1500, avenue Du-charme, Montréal, P.Q.Collège Vanier, 821, boulevard Ste-Croix, St-Laurent, P.Q.Rabbinical College of Canada, 6405, avenue Westbury, Montréal.P.Q.Lower Canada College, 4090, avenue Royale, Montréal (H4A 2M5) P.Q.Loyola High School.Montréal, P.Q.Y.M.& Y.W.H.A.of Montreal, 5500, ave Westhurv, Montréal, P.Q.Fr.McDonald-HoIv Cross High School, 950, rue Fraser, St-Laurent, Montréal (378) P.Q.The Akiva School, 5500.ave Westburv, Montréal (H3W 2W8) P.Q.et transport d'écoliers âgés de trois (3) à douze (12) ans de leurs domiciles aux écoles « Jewish People's Schools & Peretz Schools » situées au 5270, avenue Van Horne.Montréal.P.Q., et retour.Territoire: Ce service sera fourni dans les municipalités suivantes: Côte St-Luc.Hampstead, Montréal (No-tre-Dame-de-Grùce et Cartierville), St-Laurent, Mont-Royal, Ville de Laval (Cho-medey) et Outremont.Modification - droit additionnel: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec d'ajouter à son permis le service de transport suivant: Classe: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat -Service : De Montréal a Rivière-du-Loup, pour le transport de vermiculite.pour le compte de Premier Peat Moss Corporation, et retour.Restriction : Le requérant n'aura le droit qu'A l'utilisation d'un seul camion.Supplement 30 to Tariff 250-C: (Automobile Parts)._ ;_ .Supplement 12 to Tariff 261-C: (General Commodities)., , Supplement 16 to Tariff 273 and supplement 1 to Tariff 273-A (Pole-Trailer Tariff).Supplement 17 to Tariff 274-C: (Bulk Commodity Tariff).Supplement 8 to Tariff 290: (Air Freight).Supplement 14 to Tariff 368: (Class and Commodity Tariff).Supplement 9 to Tariff 566-B: (Class Supplement 23 to Tariff 630-A: (Container Tariff).Supplement 10 to Tariff 7i0 liège social.Donné à Montréal, P.Q.ce 20e jour de décembre 1973.Le président, 56184-0 Thomas S.Gillespie.ASSOCIATION B.C.S.B.C.S.ASSOCIATION Notice is hereby given that \"ASSOCIATION B.C.S.\u2014 B.C.S.ASSOCIATION\" incorporated by letters patent dated May 23rd, 1973 has established its office at Lennoxville, in the Province of Québec.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, P.Q., this 20th day of December, 1973.Thomas S.Gillespie, 56184-o President.CHASSE, TREMBLAY.DESCHENES, PINEAU ET ASSOCIES INC.Avis est donné que la compagnie « CHASSE, TREMBLAY, DESCHENES, PINEAU ET ASSOCIES INC.» constituée en corporation sous la première partie de la Loi des compagnies, par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives du Québec, en date du dix décembre mil neuf cent soixante-treize (1973), a établi son bureau au numéro 229 du boulevard Lasalle, à Baie Comeau.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Baie Comeau, ce 30e jour de janvier, mil neuf cent soixante-quatorze (1974).Le président, Jean-Ci.ai de Tremblay.56185-o 735415 CHASSE, TREMBLAY, DESCHENES, PINEAU ET ASSOCIES INC.Notice is herebv given that the company \"CHASSE, TREMBLAY, DESCHENES, PINEAU ET ASSOCIES INC.\" incorporated under Part I, of the Companies Act by letters patents bearing date the ten of December, nineteen hundred and seventy-three (1973) issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of Québec, has established ils head office at number 229 LaSalle Boulevard, in the City of Baie Comeau.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Dated at Baie Comeau, this 30th day of January, nineteen hundred and seventy-four (1974).Jean-Claude Tremblay, President.56185-0 735415 CONSTRUCTION MARSELEM INC.Avis est par la présente donné que « CONSTRUCTION MARSELEM INC.» a changé son siège social du 753 est.rue Jarry au 8102 rue Saint-Denis, en les cité et district de Montréal.Montréal, le 9 novembre 1973.Le secrétaire, Jacques Laurent.56186-0 2759-70 ANDRE COURSOL INC.Avis est donné que la compagnie « ANDRE COURSOL INC.», constituée en corporation en date du 10 octobre 1973 par lettres patentes, et ayant son siège social dans la Cité de Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 9861 de la rue Foucher.l'a transporté au numéro 9361 de la rue Foucher.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Montréal, ce 11 février 1974.(Sceau) Le secrétaire, 56187-0 Carmelle Fii.iatrault-Coursol.CONSTRUCTION MARSELEM INC.Notice is herebv given that \"CONSTRUCTION MARSELEM INC.\" has transferred its head office from 753 Jarry Street East to 8102 Saint-Denis Street, in the city and district of Montreal.Montreal.November 9.1973.Jacques Laurent, Secretary.501S6-O 2759-7C ANDRE COURSOL INC.Notice is hereby given that \"ANDRE COURSOL INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated October 10th, 1973, has moved its head office from 9861 Foucher Street in the City of Montreal to 9361 Foucher Street in the City of Montreal.\" From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the Company as being its head office.Montreal, February 11, 1974.(Seal) Cahmelle Filiatrault-Coursol, 56187-0 Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n° 9 1721 PROMOTIONS CO-MO QUEBEC INC.La compagnie « PROMOTIONS CO-MO QUEBEC INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Québec, au numéro 273, 71e Rue est, Charlesbourg.Le secrétaire, Mme Jeannette P.Collin.56179-0 714807 PROMOTIONS CO-MO QUEBEC INC.Notice is given that \"PROMOTIONS CO-MO QUEBEC INC.\" has transferred its head office from Québec, to 273 - 71st Street East, Charlesbourg.Mrs.Jeannette P.Collin, Secretary.56179 714807 ENTREPRISES R.& G.ST.LAURENT INC.Avis est donné que la compagnie « ENTREPRISES R.& G.ST.LAURENT INC.» constituée en corporation sous la première partie de la Loi des compagnies, par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives du Québec, en date du vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-treize (1973) et ayant son siège social à Hauterive, a établi son bureau au numéro 21-A de la rue Albanel, à Hauterive.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Baie-Comeau ce 31e jour de janvier mil neuf cent soixante-quatorze (1974).Le président, Réal St.Laurent.56190-o 735202 ENTREPRISES R.& G.ST.LAURENT INC.Notice is hereby given that the company \"ENTREPRISES R.& G.ST.LAURENT INC.\" incorporated under Part I, of the Companies Act by letters patents bearing date the twenty third day of November nineteen hundred and seventy-three (1973) issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives and having its head office in Hauterive established its head office at number 21-A of Albanel Street, in the city of Hauterive.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Dated at Baie-Comeau, this à 1st day of January nineteen hundred and seventy-four (1974).Real St.Laurent, President.56190-o 735202 ROBERT & GILLES DEMERS INC.Avis est donné que la compagnie « ROBERT & GILLES DEMERS INC.», constituée en corporation par lettres patentes en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, en date du 3 avril 1973, et ayant son siège social dans la paroisse St-Louis-de-Terrebonne a établi son bureau au numéro 1460 de la rue Du Buisson.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considère par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Terrebonne, ce lie jour de février 1974.Le président, 56191-0 Robert Demers.ROBERT & GILLES DEMERS INC.Notice is hereby given that \"ROBERT & GILLES DEMERS INC.\", incoiporated under Part 1 of the Companies Act by letters patent dated April 3.1973, has established its head office at 1460 Du Buisson Street, St-Louis of Terrebonne, district of Terrebonne.From and after the date of the present notice the said office is considered by the company as being its head office.Given at Terrebonne, this 11th day of February 1974.Robert Demers, 56191-0 President.LABORATOIRE DU DR.RENAUD (DIVISION CANADA) INC.Avis est donné que la compagnie ' LABORATOIRE DU DR.RENAUD (DIVISION CANADA) INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 20 février 1967, et ayant son siège social à Ste-Foy, où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au 2873 chemin Ste-Foy, l'a transporté à 2620, rue Dalton, Ste-Foy.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Québec, le 10 décembre 1973.(Sceau) Le secrétaire-trésorier, 56192-0 Louise G.Cloutier.LABORATOIRE DU DR.RENAUD (DIVISION CANADA) INC.Notice is hereby given that \"LABORATOIRE DU DR.RENAUD (DIVISION CANADA) INC.\", incorporated by letters patent dated February 20, 1967 and having its head office in Ste.Foy where its office was located until the present day, at 2873 Ste.Foy Road has transferred said office to 2620 Dalton Street, Ste.Foy.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being its head office.Québec, December 10, 1973.(Seal) Louise G.Cloutier, 56192-o Secretary-treasurer. 1722 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March S, 197j, Vol.106, No.9 LES ENTREPRISES MACKBEL INC.La compagnie « LES ENTREPRISES MACKBEL INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 1257, rue Curé-Poirier, Longueuil, au numéro 5285, rue Pierre Bernard, Montréal.La secrétaire, Ginette Leblond Lebel.56189-0 722857 LABORATOIRE MANICOUAGAN INC.Avis est donné que la compagnie « LABORATOIRE MANICOUAGAN INC.» constituée en corporation sous la première partie de la Loi des compagnies, par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives du Québec en date du dix décembre mil neuf cent soixante-treize (1973), a établi son bureau au numéro 229 boulevard LaSalle, à Baie-Comeau.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Baie-Comeau, et 30e jour de janvier mil neuf cent soixante-quatorze (1974).Le président.56193-0 Jean Claude Tremblay.ASSURANCES TOMENSON SAUNDERS WHITEHEAD LIMITEE TOMENSON SAUNDERS WHITEHEAD INSURANCE LIMITED Avis est donné par les présentes que la compagnie « ASSURANCES TOMENSON SAUNDERS WHITEHEAD LIMITEE \u2014 TOMENSON SAUNDERS WHITEHEAD INSURANCE LIMITED » a transféré son siège social de la Place Ville Marie, suite 628, en la ville de Montréal, à Place du Canada, suite 950, en la ville de Montréal.Montréal, le 14 janvier 1974.Le secrétaire, 56222 J.S.Cameron.LES ENTREPRISES MONT BRUNO INC.MONT BRUNO ENTERPRISES INC.Avis est donné que la compagnie « LES ENTREPRISES MONT BRUNO INC.\u2014 MONT BRUNO ENTERPRISES INC.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies en date du dix-sept février mil neuf cent soixante-dix (1970), et ayant son siège social dans la ville de Saint-Bruno où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 1107 de la rue Goyer, l'a transporté au numéro 1820 de la rue Southmount.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Saint-Bruno, ce 5 février 1974.(Sceau) La présidente.Mme Françoise Labbê-Bélanger.56225-0 676-70 LES ENTREPRISES MACKBEL INC.Notice is given that \"LES ENTREPRISES MACKBEL INC.\" has transferred its head office from 1257 Curé-Poirier Street, Longueuil, to 5285 Pierre-Bernard Street, Montreal.Ginette Leblond Lebel, Secretary.56189 722857 LABORATOIRE MANICOUAGAN INC.Notice is hereby given that the company \"LABORATOIRE MANICOUAGAN INC.\" incorporated under Part I, of the Companies Act at by letters patents bearing date the tenth day of December nineteen hundred and seventy three (,1973, issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of Québec has established its Head office at number 229 LaSalle Boulevard, in Ihe city of Baie-Comeau.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Dated at Baie-Comeau, this 30th day of January nineteen hundred and seventy-four (1974).Jean Claude Tremblay.56193 President.ASSURANCES TOMENSON SAUNDERS WHITEHEAD LIMITEE TOMENSON SAUNDERS WHITEHEAD INSURANCE LIMITED Notice is hereby given that \"ASSURANCES TOMENSON SAUNDERS WHITEHEAD LIMITEE \u2014 TOMENSON SAUNDERS WHITEHEAD INSURANT'F, LIMITED\" ha.moved its head office from Suite 628.Place Ville Marie, in the City of Montreal, to Suite 950, Place du Canada, in the City of Montreal.Montreal, 14 January 1974.J.S.Cameron, 56222-0 Secretary.LES ENTREPRISES MONT BRUNO INC.MONT BRUNO ENTERPRISES INC.Notice is given that \"LES ENTREPRISES MONT BRUNO INC.\u2014MONT BRUNO ENTERPRISES INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act on the seventeenth day of February one thousand nine hundred seventy (1970), and having its head office in the Town of St.Bruno where its office was located until the present day at 1107 Goyer Street, has transferred said office to 1820 Southmount Street.From the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given in St.Bruno, this 5th of February, 1974.(Seal) Mrs.Françoise Labbê-Bélanger, President.56225 676-70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n° 9 1723 ECHAFFAUDAGES DU-FOR INC.DU-FOR SCAFFOLDS INC.La compagnie «ECHAFFAUDAGES DU-FOR INC.\u2014 DU-FOR SCAFFOLDS INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 117, rue Conrad, Laval, au numéro 9601, boulevard St-Laurent, Montréal.Le secrétaire, Jacques Fortin.56223-o 716639 ECHAFFAUDAGES DU-FOR INC.DU-FOR SCAFFOLDS INC.Notice is hereby given that \"ECHAFFAUDAGES DU-FOR INC.\u2014 DU-FOR SCAFFOLDS INC.\" has moved its head office from 117 Conrad Street, Laval, to 9601 St.Laurent Boulevard, Montreal.Jacques Fortin, Secretary.56223 716639 SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE Avis est donné que la compagnie « SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE » a transféré son siège social du numéro 5178, boulevard St-Laurent, Montréal, à la huitième avenue, Val Morin.Le secrétaire-trésorier.Patricia Guy.56224 5202-65 PIRANO REALTIES LTD.IMMEUBLES PIRANO LTEE Avis est par les présentes donné que la compagnie « PIRANO REALTIES LTD.\u2014 IMMEUBLES PIRANO LTEE », constituée en corporation par lettres patentes en date du 15e jour de décembre 1972, et ayant son siège social en la ville de Montréal, où son bureau était situé au numéro 1, Place Ville Marie, suite 3635, l'a transféré au numéro 3901 Jean Talon ouest, en les ville et district de Montréal, province de Québec.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Fait à Montréal, ce 31e jour de janvier 1974.Le secrétaire, Serge Joyal.56226 726580 RUSTOP AUTOMOTIVE RUSTPROOFING (MONTREAL) LIMITED ANTIROUILLE AUTOMOTEUR RUSTOP (MONTREAL) LIMITEE Avis est par les présentes donné que la compagnie « RUSTOP AUTOMOTIVE RUSTPROOFING (MONTREAL) LIMITED \u2014 ANTIROULLLE AUTOMOTEUR RUSTOP (MONTREAL) LIMITEE », constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies le 29e jour de novembre 1973, et ayant son siège social en la ville de Montréal, a établi son bureau au numéro 596, avenue Grosvenor.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Fait à London.Ontario, ce 28e jour de janvier 1974.(Sceau) Le secrétaire-trésorier.56248 Charlotte L.Kurn.SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE Notice is given that \"SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE\" has transferred its head office from 5178 St.Lawrence Boulevard, Montreal, to Eight Avenue, Val Morin.Patricia Guy, Secretary-treasurer.56224-0 5202-65 PIRANO REALTIES LTD.IMMEUBLES PIRANO LTEE Notice is herebv given that \"PIRANO REALTIES LTD.\u2014 IMMEUBLES PIRANO LTEE\", incorporated by letters patent on the 15th day of December, 1972, and having its head office in the City of Montreal, where its office was situated at 1 Place Ville Marie, Suite 3635, has moved it to 3901 Jean-Talon West, in the City and District of Montreal, Province of Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 31st day of January, 1974.Serge Joyal, Secretary.56226-0 726580 RUSTOP AUTOMOTIVE RUSTPROOFING (MONTREAL) LIMITED ANTIROUILLE AUTOMOTEUR RUSTOP (MONTREAL) LIMITEE Notice is hereby given that \"RUSTOP AUTOMOTIVE RUSTPROOFING (MONTREAL) LIMITED \u2014 ANTIROUILLE AUTOMOTEUR RUSTOP (MONTREAL) LIMITEE\", incorporated under the provisions of Part I of the Companies Act on the 29th day of November, 1973, and having its head office in the City of Montreal, has established its office at 596 Grosvenor Avenue.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at London, Ontario, this 28th day of January, 1974.(Seal) Charlotte L.Kurn, 56248-0 Secretary-Treasurer. 1724 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 2, Mi, Vol.106.No.9 THEROUX AUTOMOBILES LTEE La compagnie «THEROUX AUTOMOBILES LTEE » donne avis qu'elle a changé son siège social de Saint-David, au numéro 297.route Marie-Victorin.Yamaska Est.La secretaire.Mme Denise Théroux.56228-0 1352-67 DAIGLE AQUA INC.Avis est donné que la compagnie « DAIGLE AQUA INC.», constituée en corporation par lettres patentes sous la Loi des compagnies en date du 2e jour d'octobre 1973, et ayant son siège social dans la ville de Longueuil, a établi son bureau au numéro 1369 du boulevard Ste-Foy.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Longueuil.ce 2e jour d'octobre 1973.Le secrétaire.G.Gordon Kohl.56227-0 734330 THEROUX AUTOMOBILES LTEE Notice is given that \"THEROUX AUTOMOBILES LTEE\" has transferred its head office from St.David to 297 Marie-Victorin Road, Yamaska East.56228 Mrs.Denise Théroux, Secretary.1352-67 DAIGLE AQUA INC.Notice is given that \"DAIGLE AQUA INC.\", incorporated by letters patent under the Companies Act on the 2nd day of October, 1973, and having its head office in the City of Longueuil, has established its office at 1369 SU.Foy Boulevard.From the date of this notice, the said office shall be considered by the company as its head office.Given in Longueuil, this 2nd day of October, 1973.G.Gordon Kohl, Secretary.56227 734330 Avis divers Miscellaneous Notices L'EVEQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE ROUYN-NORANDA THE ROMAN CATHOLIC BISHOP OF ROUYN-NORANDA Avis est donné qu'en vertu de l'article 3 de la Loi des évéques catholiques romains, Statuts refondus, 1964, chapitre 304, il a été accordé par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives des lettres patentes en date du 22 janvier 1974, constituant en corporation « L'EVEQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE ROUYN-NORANDA \u2014THE ROMAN CATHOLIC BISHOP OF ROUYN-NORANDA'.Le siège social de la corporation est situé à Rouyn, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Le ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives, William Tftley.56258-0 LPE; 1-74 MONASTERE DES URSULINES D'AMQUI Avis est donné qu'en vertu de la loi constituant en corporation P« Union canadienne des Moniales de l'Ordre de Sainte-Ursule», chapitre 150 des lois de 1955-1956, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province, des lettres patentes supplémentaires en date du 24 octobre 1973, à la corporation « MONASTERE DES URSULINES D'AMQUI » modifiant les dispositions de ses lettres patentes originaires.Le Chanoine, 56259-e Jean Rondeau.L'EVEQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE ROUYN-NORANDA THE ROMAN CATHOLIC BISHOP OF ROUYN-NORANDA Notice is given that pursuant to section 3 of the Roman Catholic Bishops Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 304, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, has issued letters patent dated January 22, 1974, incorporating \"L'EVEQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE ROUYN-NORAN-; DA \u2014THE ROMAN CATHOLIC BISHOP OF ROUYN-NORANDA\".The head office of said corporation is located in Rouyn, Judicial District of Rouyn-Noranda.William Tetlev, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.56258 LPE: 1-74 MONASTERE DES URSULINES D'AMQUI Notice is given that pursuant to the Act to incorporate l'\"Union canadienne des Moniales de l'Ordre de Sainte-Ursule\", Chapter 150 of the Statutes of 1955-1956, the Lieutenant-Governor in Council has granted to the \"MONASTERE DES URSULINES D'AMQUI\" supplementary letters patent, dated October 24, 1973, modifying the provisions of its original letters patent.Jean Rondeau, 56259 Canon. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1974, 106' année, n' 9 1725 LA CORPORATION MINIERE OMNIA THE OMNIA MINING CORPORATION Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies et de la Loi des compagnies minières, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 3e jour de janvier 1974, à la compagnie « CENTRAL PATRICIA MINES (QUE-BEC) LIMITED (No personal liability) », constituée en corporation par lettres patentes en date du lie jour de décembre 1956, 1° changeant son nom en celui de « LA CORPORATION MINIERE OMNIA \u2014 THE OMNIA MINING CORPORATION » ; 2° changeant 500,000 actions d'une valeur au pair de $1 chacune en 500,000 actions sans valeur au pair; la valeur totale de l'émission desdites actions sans valeur au pair ne doit pas excéder le montant ou la valeur de 8500,000 ; 3° modifiant les dispositions de ses lettres patentes.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.56158 13930-56 LA CORPORATION MINIERE OMNIA THE OMNIA MINING CORPORATION Notice is given that, under Part I of the Companies Act and the Mining Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 3rd day of January, 1974, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to \"CENTRAL PATRICIA MINES (QUEBEC) LIMITED (No personal liability)\", incorporated by letters patent dated the 11th day of December, 1956, 1.changing its name into that of \"LA CORPORATION MINIERE OMNIA\u2014THE OMNIA MINING CORPORATION\"; 2.changing 500.000 shares of the par value of SI each into 500,000 shares without par value; the aggregate consideration for the issue of the said shares without par value shall not exceed in amount or value the sum of $500,000 ; 3.modifying the provisions of its letters patent.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.56158-0 13930-56 CLUB AUTO-NEIGE SNOROVERS DE PERKINS Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de décembre 1973, constituant en corporation sans capital-actions, les membres actuels de « CLUB AUTO-NEIGE SNOROVERS DE PERKINS », déjà constituée en corporation le ou vers le 21 juin 1972, en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus, 1964, chapitre 298).Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $10,000.Le siège social de la nouvelle corporation est à Perkins, district judiciaire de Hull.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.56158-0 735819 CLUB AUTO-NEIGE SNOROVERS DE PERKINS The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice that under Part III of the Companies Act, he has issued letters patent, dated the 20th day of December, 1973, incorporating as a corporation without share capital, the present members of \"CLUB AUTO-NEIGE SNOROVERS DE PERKINS\", already incorporated on or about June 21, 1972, under the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 298).The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $10,000.The head office of the new corporation is located in Perkins, Judicial District of Hull.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.56158 735819 Corporation municipale du village de Fossambault sur le Lac Avis public est, par les présentes, donné que le conseil de la corporation municipale du village de Fossambault sur le Lac a adopté, à l'unanimité, une résolution autorisant cette municipalité à présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil pour être constituée en ville, par lettres patentes.Nom de la ville projetée: Ville de Fossambault sur le Lac; limite de la ville projetée: territoire actuel de la municipalité du village de Fossambault sur le Lac.comté de Portneuf; population: répertoire municipal: 135 habitants.Les procureurs de la municipalité, Desjardins, Lacroix, 56204-o Routhier & Bouchard.Municipal corporation of the village of Fossambault sur le Lac Public notice is hereby given that the council of the municipal corporation of the village of Fossambault sur le Lac have passed resolution authorizing this municipality to present a petition to the Lieutenant-Governor in Council to be incorporated as a town municipality by letters patent.Name of the proposed town: the Town of Fossambault sur le Lac; limits of the proposal town: the actual territory of the village of Fossambault sur le Lac, county of Portneuf; population of the proposal town: 135, last provincial census.Desjardins, Lacroix, Routhier & Bouchard, 56204-o Attorneys for the municipality. 1726 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol- 106, No.9 Le Conseil Ste-Foy (5685) des Chevaliers de Colomb de Ste-Foy Le « Conseil Ste-Foy (5685) des Chevaliers de Colomb de Ste-Foy >, 3360 de La Pérade.Ste-Foy, Québec 10, donne avis, par les présentes, qu'il possède son siège social à l'adresse susmentionnée et qu'il se prévaut des dispositions de la Loi concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec (1-2 Elizabeth II, chap.134) à partir du 5 décembre 1973.Ste-Foy, le 5 décembre 1973.Le Grand Chevalier, Patrick Cullen.Le secrétaire-archiviste, Gérard Poitras.56197-0 CC-10-73 Le Conseil No 6412 Matagami des Chevaliers de Colomb de Matagami Le « Conseil No 6412 Matagami des Chevaliers de Colomb de Matagani » C.P.1352 donne avis, par les présentes, qu'il possède son siège social à l'adresse susmentionnée et qu'il se prévaut des dispositions de la Loi concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec (1-2 Elizabeth II, chap.134) à partir du 10 septembre 1972.Matagami.le 6 novembre 1973.Le Grand Chevalier, Joseph Domingue.Le secrétaire-archiviste, Rénald Léveillé.56200-o CC-8-73 Ste.Foy Council No.5685 of the Knights of Colombus Notice is hereby given that \"Ste.Foy Council No.56S5 of the Knights of Columbus\", of Ste.Foy, 3360 de La Pérade, Ste.Foy, Québec 10.has its head office at the aforesaid address and that it avails itself of the provisions of the Act respecting the Knights of Columbus of the Province of Québec (1-2 Elizabeth II, Chapter 134) from December 5, 1973.Ste.Foy, December 5, 1973.Patrick Cullen, Grand Knight.Gérard Poitras, Registrar.56197 CC-10-73 Matagami Council No.6412 of the Knights of Columbus Notice is hereby given that \"Matagami Council No.6412 of the Kinghts of Columbus of Matagami\".Post Office Box 1352, has its head office at the aforesaid address and that it avails itself of the provisions of the Act respecting the Kinghts of Columbus of the Province of Québec (1-2 Elizabeth II, Chapter 134) from September 10.1972.Matagami, November 6, 1973.Joseph Domingue, Grand Knight.Rénald Léveillé, Registrar.56200 CC-8-73 Le Conseil No 3147 Ville LaSalle des Chevaliers de Colomb de Ville LaSalle Le « Conseil No 3147 Ville LaSalle des Chevaliers de Colomb » de Ville Lasalle 7710 Boul.LaSalle donne avis, par les présentes, qu'il possède son siège social à l'adresse susmentionnée et qu'il se prévaut des dispositions de la Loi concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec (1-2 Elizabeth II.chap.134) à partirdu 2 novembre 1973.LaSalle.le 2 novembre 1973.Le Grand Chevalier.Robert Perras.Le secrétaire-archiviste, René Forest.56201-o CC-1457-53 City of LaSalle Council No.3147 of the Knights of Columbus Notice is hereby given that \"City of LaSalle Council No.3147 of the Knights of Columbus\" of the City of LaSalle.7710 LaSalle Boulevard, has its head office at the aforesaid address and that it avails itself of the provisions of the Act respecting the Knights of Columbus of the Province of Québec (1-2 Elizabeth II, Chapter 134) from November 2.1973.LaSalle, November 2, 1973.Robert Perras, Grand Knight.René Forest, Registrar.56201 CC-1457-53 Ministère des Terres et Forêts Cadastre Department of Lands and Forests Cadastre Canton de Grantham Cadastre officiel du canton de Grantham, municipalité \u2022le la cité de Drummondville, division d'enregistrement de Drummond.Township of Grantham Official cadastre of township of Grantham, municipality of the city of Drummondville, registration division of Drummond. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 19U, 106' année, n° 9 1727 Avis est par la présente donné que les lots 126-3-107 à 126-3-113 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 28 janvier 1974.Pour le sous-ministre, 56161-0 Benoît Grimard, a.-o.Notice is hereby given that lots 126-3-107 to 126-3-113 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 28, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 56161-0 For the Deputy Minister.Canton de La Minerve Cadastre officiel du canton de La Minerve, municipalité du canton de La Minerve, division d'enregistrement de Labelle.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 90-1 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 31 janvier 1974.Pour le sous-ministre.56161-0 Benoît Grimard, a.-g.Township of La Minerve Officiai cadastre of township of La Minerve, municipal- .ity of township of La Minerve, registration division of Labelle.Notice is hereby given that a part of lot 90-1 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 31, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 56161-0 For the Deputy Minister.Paroisse de L'Ange-Gardien Cadastre officiel de la paroisse de L'Ange-Gardien, municipalité de la paroisse de L'Ange-Gardien, division d'enregistrement de Montmorency.Avis est par la présente donné que les lots 138-13 à 138-18 et qu'une partie des lots 138-12, 138-19, 138-30, 138-32, 138-33 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 12 novembre 1973.Pour le sous-ministre, 56161-0 Benoît Grimard, a.-g.Parish of L'Ange-Gardien Official cadastre of the parish of L'Ange-Gardien, municipality of the parish of L'Ange-Gardien, registration division of Montmorency.Notice is herebv given that lots 138-13 to 138-18 and that a part of lots 138-12, 138-19, 138-30, 138-32, 138-33 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, November 12, 1973.Benoît Grimard, a.-g., 56161-0 For the Deputy Minister.Paroisse de Laprairie de la Madeleine Cadastre officiel de la paroisse de Laprairie de la Madeleine, municipalité de la ville de Sainte-Catherine, division d'enregistrement de Laprairie.Avis est par la présente donné que le lot 617-89 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 30 janvier 1974.Pour le sous-ministre, 56161-0 Benoît Grimard, a.-g.Parish of Laprairie de la Madeleine Officiai cadastre of the parish of Laprairie de la Madeleine, municipality of the town of Sainte-Catherine, registration division of Laprairie.Notice is hereby given that lots 617-89 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 30, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 56161-0 For the Deputy Minister.Canton de Roberval Cadastre officiel du canton de Roberval, municipalité de la cité de Roberval, division d'enregistrement de Lac Saint-Jean-Ouest.Avis est par la présente donné que les lots 69-45, 69-46, 69-55, 69-56, 70-99 à 70-101, 70-107 à 70-110 et qu'une partie des lots 69-42, 69-43, 69-44, 69-47, 69-48, 69-50, 69-52 à 69-54, 70-94 à 70-98, 70-102_à 70-106 du rang B sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 13 novembre 1974.Pour le sous-ministre, 56161-0 Benoît Grimard, a.-g.Township of Roberval Official cadastre of township of Roberval, municipality of the city of Roberval, registration division of Lac-Saint-.Iean-Ouest.Notice is herebv given that lots 69-45, 69-46, 69-55, 69-56, 70-99 to 70-101, 70-107 to 70-110 and that a part of lots 69-42, 69-43, 69-44, 69-47 , 69-48, 69-50, 69-52 to 69-54, 70-94 to 70-98, 70-102 to_70-106 of range B are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, November 13.1974.Benoît Grimard, a.-g., 56161-0 For the Deputy Minister. 1728 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 2.1974, Vol.10n, No.9 Canton de Roberval Cadastre officiel du canton de Roberval, municipalité de la cité de Roberval, division d'enregistrement de Lac St-Jean Ouest.Avis est par la présente donné que le lot 70-106-1 du rang B est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 21 janvier 1974.Pour le sous-ministre, 56161-0 Benoit Grimard, a.-g.Ville de Rouyn Cadastre officiel de la ville de Rouyn.municipalité de la cité de Rouyn, division d'enregistrement de Rouyn-Noranda.Avis est par la présente donné que les lots 9-764-17 à 9-764-20, 9-764-42 à 9-764-46 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 15 janvier 1974.Pour le sous-ministre, 56161-0 Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Saint-Ambroise-de-Ia-Jeune-Lorette Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, municipalité de la ville de Québec, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que la partie restante du lot 540-3 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 6 février 1974.Pour le sous-ministre, 56161-0 Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Saint-Antoine-de-Longucuil Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil, municipalité de la ville de Greenfield Park, division d'enregistrement de Chambly.Avis est par la présente donné que les lots 213-132, 214-112 à 214-114, 215-139 à 215-143, 216-124 à 216-126 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 29 janvier 1974.Pour le sous-ministre, 56161-0 Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Saint-Flavien Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Flavien, municipalité du village de Saint-Flavien, division d'enregistrement de Lotbinière.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 414-29 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 5 février 1974.Pour le sous-ministre, 56161-o Benoît Grimard, a.-g.Township of Roberval Official cadastre of township of Roberval, municipality of the city of Roberval, registration division of Lac St.Jean Ouest.Notice is hereby given that lot 70-106-1 of range B is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 21, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 56161-o For the Deputy Minister.Town of Rouyn Official cadastre of the town of Rouyn, municipality of the city of Rouyn, registration division of Rouyn-Noranda.Notice is hereby given that lots 9-764-17 to 9-764-20, 9-764-42 to 9-764-46 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.January 15, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 56161-o For the Deputy Minister.Parish of Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette Official cadastre of the parish of Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, municipality of the town of Québec, registration division of Québec.Notice is hereby given that the remaining part of lot 540-3 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, February 6, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 56161-0 For the Deputy Minister.Parish of Saint-Antoine-de-Longueuil Official cadastre of the parish of Saint-Antoine-de-Longueuil, municipality of the town of Greenfield Park, registration division of Chambly.Notice is hereby given that lots 213-132, 214-112 to 214-114, 215-139 to 215-143, 216-124 to 216-126 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 29, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 56161-o For the Deputy Minister.Parish of Saint-Flavien Official cadastre of the parish of Saint-Flavien, municipality of village of Saint-Flavien, registration division of Lotbinière.Notice is hereby given that a part of lot 414-29 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, February 5, 1974.Bevoît Grimard, a.-g., 56161-0 For the Deputy Minister. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n° 9 1729 Paroisse de Saint-Cermain-de-Rimouski Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Germain-de-Riraouski, municipalité de la cité de Rimouski, division d'enregistrement de Rimouski.Avis est par la présente donné que les lots 211-55 à 211-59, 211-67 à 211-77, 211-87, 211-88, 211-93, 211-94, 211-99.211-100.211-105, 211-249 à 211-253, 211-255, 211-57-1, 211-74-1, 211-74-2, 211-60-3.211-78-2, 211-78-3, 211-106-2 et qu'une partie des lots 211-60, 211-66, 211-78, 211-86.211-106 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 28 janvier 1974.Pour le sous-ministre, 56161-o Benoît Grimard, a.-g.Parish of Saint-Germain-de-Rimouski Official cadastre of the parish of Saint-Gerraain-de-Rimouski.municipality of the city of Rimouski, registration division of Rimouski.Notice is hereby given that lots 211-55 to 211-59, 211-67 to 211-77, 211-87, 211-88,211-93,211-94.211-99, 211-100, 211-105.211-249 to 211-253, 211-255, 211-57-1, 211-74-1, 211-74-2, 211-60-3, 211-78-2, 211-78-3, 211-106-2 and that a part of lots 211-60, 211-66, 211-78, 211-86, 211-106 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.January 28.1974.Benoît Grimard, a.-g., 56161-0 For the Deputy Minister.Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Mathieu-de-lîeloeil, municipalité de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil, division d'enregistrement de Verchères.Avis est par la présente donné que le lot 298-2 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 25 janvier 1974.Pour le sous-ministre, 56161-o Benoît Grimard, a.-g.Parish of Saint-Mathieu-de-Beloeil Official cadastre of the parish of Saint-Mathieu-de-Beloeil, municipality of the parish of Saint-Mathieu-de-Beloeil, registration division of Verchères.Notice is hereby given that lot 238-2 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.January 25.1974.Benoît Grimard, a.-g., 56161-0 For the Deputy Minister.Paroisse de Saint-Rémi Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Rémi, municipalité de la paroisse de Saint-Rémi, division d'enregistrement de Napierville.Avis est par la présente donné que le lot 212-190 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 25 janvier 1974.Pour le sous-ministre, 56161-0 Benoît Crimard, a.-g.Parish of Saint-Rémi Official cadastre of the parish of Saint-Rémi, municipality of the parish of Saint-Rémi, registration division of Napierville.Notice is hereby given that lot 212-190 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 25, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 56161-o For the Deputy Minister.Canton de Villeneuve Cadastre officiel du canton de Villeneuve, municipalité de Val-des-Bois *, division d'enregistrement de Papineau.Avis est par la présente donné que les lots la et 2a du rang I sont ajoutés et que les lots 1 à 23 du rang A, 15 à 27 du rang B, 20 à 26 du rang C, 1 à 23 du rang I nord, 1 à 23 du rang II nord, 1 à 22 du rang III nord, 1 à 22 du rang IV nord, 1 à 21 du rang V nord, 1 à 21 du rang VI nord, 28 à 46 du village de Les Grandes-Chutes sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 24 janvier 1974.Township of Villeneuve Official cadastre of township of Villeneuve, municipality of Val-des-Bois *, registration division of Papineau.Notice is hereby given that lots la and 2a of range I arc added and that lots 1 to 23 of range A, 15 to 27 of range B, 20 to 26 of range C, 1 to 23 of range I north, 1 to 23 of range II north, 1 to 22 of range III north, 1 to 22 of range IV north, 1 to 21 of range V north, 1 to 21 of range VI north, 28 to 46 of village of Les Grandes-Chutes are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.January 24, 1974.56161-o Pour le sous-ministre, Benoît Grimard, a.-g.56161-o Benoît Grimard, a.-g., For the Deputy Minister. 1730 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.9 Régie de l'assurance-maladie du Québec Québec Health Insurance Board List compiled on a regional basis, of the names and business addresses of professionals who intend practising their profession outside the scope of the plan as professionals or who have ceased to practice in this capacity, as well as the date on which their withdrawal or non-participation becomes effective or ceases to become effective, published according to section 7.01 of the regulations respecting the Health Insurance Act adopted bv order in council No.27, dated January 6, 1971.Liste par région de noms et adresses d'affaires des professionnels de la santé, qui entendent exercer leur profession en dehors des cadres du régime en qualité de professionnels désengagés ou de professionnels non participants ou qui ont cessé d'exercer leur activité en cette qualité, ainsi que la date à laquelle prend effet leur désengagement ou leur non-participation ou la cessation de celle-ci, publiée conformément à l'article 7.01 des règlements concernant la Loi de Passurance-maladie, adoptés par arrêté en conseil No 27, en date du 6 janvier 1971.Professionnels désengagés Professionals withdrawn Médecins omnipraticiens General Practitioners Région de Montréal \u2014 Montreal Region Duchesne, Laurent, 75, boul.Dorchester ouest.Bureau 1017, Montréal 128, (Québec) Région de Québec \u2014 Québec Region Mino.Roland, Case postale 7395, Québec 7, (Québec) Tremblay, Jacques, 590, Saint-Cyrille ouest, Québec 6, (Québec) Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Chamard, John McLean, 1509, Sherbrooke West, Suite 18A, Montréal 109, (Québec) Région de Témiscamingue \u2014 Témiscamingue Region Bellehumeur, Claude, 10 nie McQuaig est, Rouyn, (Québec) Région de Gaspé \u2014 Gaspé Region Létourneau, Anicet, Case postale 890, Gaspé (Québec) Date effective du désengagement Effective date of withdrawal 29-01-71 30-05-71 23-05-71 16-08-72 08-06-72 07-01-74 Professionnels non participants Non-participating professionals Médecins spécialistes Medical Specialists Date effective de non-participation Effective date of non-participation Région de Montréal \u2014 Montreal Region Almudevar, Manuel, 612, St.John's Road, Suite 114, Pointe-Claire 720, (Québec) Aronovitch, Michael, 4119, Sherbrooke Street West, Montréal 215, (Québec) Barker, Charles S., 9, Nelson, Montréal 263, (Québec) Black, Donald Kenneth, Case postale 95, Hudson Heights, (Québec) Bossé, Jean, 6555, boul.Gouin ouest, Montréal 389, (Québec) Boulanger, Jean-Baptiste, 3610, avenue Atwater, Montréal 109, (Québec) Brabander, Joachim, 1390, Sherbrooke Street West, Montréal 109, (Québec) Brow, Georges-Raymond, 1374, Sherbrooke Street West, Suite 7, Montréal 109, (Québec) Browman, Mark, 7841 - 2nd Avenue, Montréal 455, (Québec) Butler, Albert-A., Medical Arts Bldg., Montréal 109, (Québec) Cantero, Antonio, 1396, Sainte-Catherine ouest, Montréal 107, (Québec) Copping, Gordon A., 724, Upper Belmont Avenue, Montréal 217, (Québec) Cordeau, Claire, 1392, Jean-Talon est, #301, Montréal 329, (Québec) David, Paul-P., 8705.rue Barbeau, Montréal 457, (Québec) Dawson, Howard L., 14, Bellevue Avenue, Westmount 217, (Québec) 01-12-70 01-12-70 01-12-70 01-12-70 24-09-72 16-04-71 01-12-70 01-12-70 30-07-71 01-12-70 01-12-70 01-12-70 06-01-73 01-12-70 01-12-70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n\" 9 1731 Professionnels non participants Non-participating professionals Médecins spécialistes Medical specialists Région de Montréal \u2014 Montreal Region Dumais, Gaston, 12245, Grenet, Suite 112, Montréal 390, (Québec) Eakin, W.W., 1538, Sherbrooke Street West, Apartment 704, Montréal 109, (Québec) Fullerton, C.W., 1414, Drummond Street, Montréal 107, (Québec) Gélinas, André, 565, Javelin, Dorval 740, (Québec) Genest, Armand, 30, boulevard St-Joseph est, Suite 818, Montréal 151, (Québec) Gold, Michael M.A., 5785, Côte des Neiges, Apartment 105, Montréal 249, (Québec) Hunt, Brian R., 1538.Sherbrooke West, Apt.622, Montréal 109, (Québec) Johnston, Kenneth B-, Main Road, Hudson, Vaudreuil (Québec) Korenberg, Lela C, 1538, Sherbrooke Street West, #601, Montréal 109, (Québec) Korenberg, Morton, Medical Arts Bldg., Montréal 109, (Québec) Kravitz, Henry, 4994, Circle Road, Montréal 248, (Québec) Larivière, Paul, 3484, avenue Laval, Montréal 130, (Québec) Legendre, J.-Henri, 969, boul.Saint-Joseph est.Appartement 3, Montréal 176, (Québec) Levy, Léonard, 3545, Côte des Neiges, app.118, Montréal 109, (Québec) Macdonald, Allison D., 3550, Côte des Neiges, Suite 110, Montréal 109, (Québec) MacFarlane, Malcolm R., 1538, Sherbrooke Street West, #601, Montréal 109, (Québec) Maguire, J.Gordon, 4485, Sherbrooke ouest, Westmount, Montréal 215, (Québec) Manseau, J.Arthur, 960, boulevard Saint-Joseph est, Montréal 176, (Québec) Mason, Edward Halton, 3465, Côte des Neiges Road, Suite 81, Montréal 109, (Québec) Melhado, Gérald Carlton, 900, Sherbrooke Street West, Montréal 110, (Québec) Moll, Albert Edward, 3550, Côte des Neiges Road, Suite 570, Montréal 109, (Québec) Montgomery, Lome C, 556, Grosvenor Avenue, Montréal 217, (Québec) Morin, Paul, 680, Saint-Denis, Saint-Hyacinthe, (Québec) Nadler, Norman-J., 4141, Sherbrooke Ouest, #540, Montréal 215, (Québec) Naiman, James, 4330, Sherbrooke ouest, Montréal 215, (Québec) Nerman, Yale, 1115, Sherbrooke West, Suite 1403, Montréal 110, (Québec) Pearson, Georges J.R., 5715, avenue Darlington, Appartement 1, Montréal 251, (Québec) Raginsky, Bernard B., 376, Redfern Avenue, Suite 2, Montréal 215, (Québec) Redmond, Lila, Medical Arts Bldg., #520, Montreal 109, (Québec) Robert, Paul, 3489, avenue Atwater, Appartement 6, Montréal 109, (Québec) Scott, W.Clifford M., 1260, McGregor Avenue, Suite 405, Montréal 109, (Québec) Smith, Clifton Conway, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 1020, Montréal 109, (Québec) Smith, Frederick Mclver, 3550, Côte des Neiges, Suite 640, Montréal 109, (Québec) Stein, Samuel, 1025 Pine Avenue West, Montréal 112, (Québec) Tucker, Elrie Clifford, 1390, Sherbrooke Street West, Apt.2, Montréal 109, (Québec) Région de Québec \u2014 Québec Region Lapointe, Donat, 220, Grande-Allée est, app.650, Québec 4, (Québec) Larue, Lucien, 964, Casot, Québec 6, (Québec) Parrot, Paul, 1328, avenue des Pins, Sillery, Québec 6, (Québec) Médecins omnipraticiens General Practitioners Région de Montréal \u2014 Montreal Region Archambault, Paul-A., 2805, Willowdale, Montréal 250, (Québec) Brouille, Raynald, 3775, Saint-Hubert, Appartement 10, Montréal 132, (Québec) Chevrefils, Paul-E., 7960, Saint-Denis, Montréal 327, (Québec) Cholette, Albert M., 5001, Gamier, Montréal, (Québec) Jacques, Elphège, 190, rue Principale est, Farnham, (Québec) Gordon, Lionel, 6235A, Lennox Avenue, Montréal 251, (Québec) Joannette, Jean-Paul, 4930, Mayfair, Montréal 265, (Québec) Leclaire, Yves, 4780, Côte des Neiges, Suite 32, Montréal 247, (Québec) Mayman, Abe, 5845, Côte des Neiges, Suite 690, Montréal 249, (Québec) Morgentaler, Henry, 2990, Beaugrand, Montréal 429, (Québec) Ostiguy, Jean-Paul, 450, rue Sherbrooke est, Suite 108, Montréal 132, (Québec) Date effective de non-participation Effective date of non-participation 27-03-71 15-01-71 01-12-70 01-12-70 29-01-71 01-12-70 03-01-73 31-12-70 26-08-72 01-12-70 10-06-72 01-12-70 01-12-70 06-04-73 01-12-70 26-08-72 13-02-71 01-12-70 07-01-71 01-01-71 25-04-72 01-12-70 01-12-70 01-12-70 01-03-72 03-01-71 01-12-70 01-12-70 01-12-70 03-02-71 01-12-70 01-12-70 01-12-70 01-07-72 01-12-70 13-01-71 26-12-70 01-12-70 01-05-71 02-01-71 13-12-70 01-01-74 01-12-70 15-01-72 01-12-70 01-12-70 17-12-70 05-01-71 01-12-70 1732 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 2.1974.Vol.106.No.9 Professionnels non participants Non-participating professionals Médecins omnipratiens General Practitioners Date effective de non-participation Effective date of non-participation Scott, Benjamin H., 5146, Westbury Avenue, Montreal 248, (Québec) Vines, Norman M., 1452, Bishop Street, Suite 3, Montréal 107, (Québec) Région de Troù-Rivières \u2014 Trois-Rivières Region Marcotte, Gaston, Case postale 457, Cap-de-la-Madeleine, (Québec) Région de Québec \u2014 Québec Region Rinfret, Charles-G., 3179, chemin Saintc-Foy, Sainte-Foy, Québec 10, (Québec) Samson, J.W., 725, 68c Rue est, Québec 7, (Québec) Région des Cantons de l'Est \u2014 Eastern Townships Region Grainger, Thomas R., Case postale 1500, John Manvillc Clinic, Asbestos, Richmond, (Québec) Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Beaulieu, J.-Édouard, Case postale 148, Saint-Rémy, Napierville, (Québec) Bieniecki, Irena, 531, Rockland Avenue, Montréal 153, (Québec) Bourgoin, Jean-Charles, 1248, rue Lajoie, Montréal 154, (Québec) Bourke, Edward T., 18, Thornhill Avenue, Westmount 217, (Québec) Boyles, Williams Howard, 1414, Drummond Street, Suite 422, Montréal 107, (Québec) Burns, Frank Leonard, 1414, Drummond Street, Suite 1022, Montréal 107, (Québec) Bushel), Winston C, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 1006, Montréal 109, (Québec) Caplan, Herbert, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 912 - 913, Montréal 109, (Québec) Casey, Charles-A\u201e 4695, Sherbrooke Street West, Montreal 215, (Québec) Colle, Albert Joseph, 5253, boul.Décarie, Suite 218, Montréal 248, (Québec) Coulombe, Roger, 4660, boulevard St-Joseph, Lachine, (Québec) DeGrandmont, Claude, 4934, rue Adam, Montréal 404, (Québec) Dundass, Georges M., 4545, Sherbrooke, Montréal 215, (Québec) Dundass, Roberta Phelps 4545, Sherbrooke, Montréal 215, (Québec) Elo, James-Thomas, 1414, Drummond Street, Suite 909, Montréal 107, (Québec) Felgar.Arthur, 5025.Sherbrooke West, #260, Westmount, Montréal, (Québec) Franklin, Gerald, 4078, Gage Road, Montreal 218, (Québec) Gendron, Roland, 900 Sherbrooke ouest.Suite 12, Montréal 110, (Québec) Grossman, Ronald, 5465, Queen Mary Road, Montreal (Québec) Harvey, Robert-F., 1650, Cedar Avenue, Montréal 109, (Québec) Henry.Donald Ward, 227, Kenaston Avenue, Montreal 305, (Québec) Kay, Frank A., 1538, Sherbrooke West, suite 1006, Montreal, (Québec) Kent, Léonard E., 4695, Sherbrooke Street West, Montréal 215, (Québec) Kutzman, Ernest-Abraham, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 410, Montréal 109, (Québec) Labelle, Paul, 11,271, Henri d'Arles, Montréal 389, (Québec) Lafortune, Jean-Paul, 5704, Laurendeau, Montréal 205, (Québec) Lalanne, Jean-Guy, 719, 1ère Rue, Iberville, (Québec) Lamarche.Roger, 6119, Monkland, Montréal (Québec) Lawlor, Robert, 333, Chemin Reine-Marie, Montréal 247, (Québec) Lefebvre, Pierre-L, 2225, boulevard Lapinière, Ville Brossard, (Québec) Legault.J.-Victor, 5757, Decelles, #336, Montréal 251, (Québec) Litvack, Sylvia M., 5465, Queen Mary Road, Apartment 610, Montréal 248, (Québec) Munro, David John.3550, Côte des Neiges, #400, Montréal, (Québec) Muroff.Frederick, 1414, Drummond Street, Suite 1104, Montréal 107, (Québec) Myles, Thomas A., 1538, Sherbrooke Street West, Suite 412, Montréal 109, (Québec) Orny, Sophie, 4980, Dornal Avenue, Montréal 248, (Québec) Parent, Benoit, Place Victoria, app.808, Montréal 115, (Québec) Paré, Marius, 6000, Monk, Montréal, (Québec) Pearson, Hyman H., 4780, Côte des Neiges Rd., Apartment 19, Montréal 247, (Québec) Poch, Lewis-Neville, 1, Westmount Square, Suite 346, Westmount 216, (Québec) 22-07-71 01-12-70 21-10-71 13-12-70 27-07-72 01-12-70 30-03-71 02-09-72 15-04-71 09-03-71 02-03-71 13-02-71 10-02-71 11-01-73 27-03-71 03-02-71 25-02-71 08-04-72 03-03-73 29-10-73 16-02-71 01-12-73 19-11-72 07-03-73 19-01-74 15-04-71 31-01-71 27-12-73 07-04-71 01-02-71 11-08-71 13-02-71 17-01-73 13-01-74 18-02-71 02-02-71 01-12-73 01-05-71 07-12-73 10-03-71 01-02-71 29-11-73 23-08-72 22-02-74 06-02-71 14-04-71 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n° 9 1733 Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participat ion Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Richard, Reginald, 4453, rue Ueaubien est, Montréal 409 (Québec) 18-01-74 Robinson, Wilfrid R\u201e 3410, Benny, #1.Montréal (Québec) 17-01-74 Rogers, Mervyn Allen, 4300, boulevard de Maisonneuve ouest, Appartement 702, 06-02-71 Montréal 215, (Québec) Rosen, Harry.3545 Côte Ste-Catherine, #400, Montréal (Québec) 03-02-74 Rudick, Gcrald-S., 5940, Queen Mary Road, Suite 400, Montréal 248, (Québec) 30-01-71 Samis, Philip L., 1 Place Ville-Marie, Suite 1521, Montreal 113 (Québec) 17-01-74 Stockwell, William Gordon, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 805, 09-03-71 Montreal 109, (Québec) Sykora, Oskar Paul, Dental Clinic, 1660, Cedar, Montreal 109, (Québec) 31-01-71 Van Vliet, Jonothan E., 1538, Sherbrooke Street West, Suite 805, Montréal 109, (Québec) 08-03-71 Vinet, Éphrem, 426, boulevard St-.Ioseph est, Montréal 176, (Québec) 08-02-71 Weinlandcr, Gérard H.G., 1650, Cedar, Montreal 109, (Québec) 08-10-73 Weinstcin, Paul R.5025, Sherbrooke West, #260, Montréal 260, (Québec) 01-12-73 Wise, Martin, 3860, Notre-Dame Blvd., Chomedy, (Québec) 29-11-73 Région de Québec \u2014 Québec Region Boucher, Marc, 1000, Chemin Ste-Foy, Suite 302, Québec 6, (Québec) 31-01-71 Région des Cantons de l'Est \u2014 Eastern Townships Region Dugal.Paul-Laurent, 459A, Lindsay, Drummondville, (Québec) 08-02-71 Gossehn, Viateur, 854, Belvédère sud, Sherbrooke, (Québec) 16-05-73 Laforce, Jacques, 31, King ouest.Suite 310, Sherbrooke, (Québec) 04-02-71 Leblanc, Jean-Yves, Case postale 851, Bedford, (Québec) 06-02-71 Marcoux, Jean-F., 448 rue King ouest, app.4, Sherbrooke, (Québec) 11-04-71 Olivier, Valmore H., 843, Belvédère sud, Sherbrooke, (Québec) 07-02-71 Région de l'Outaouais \u2014 Oulaouais Region Proulx, Jacques, 214, boulevard Saint-Joseph, Hull, (Québec) 05-05-71 Optométristes Optometrists Région de Montréal \u2014 Montreal Region Breton, Antonio, 1530, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe, (Québec) 31-12-70 Pharmaciens Pharmacists Région de Québec \u2014 Québec Region Auger, Raoul, 1606, Rouville, Ste-Foy, Québec 10, (Québec) 29-06-73 Laliberté, Jean, Fortierville, Lotbinière, (Québec) 26-10-72 Thibault, Urbain, 9926, Royale, Ste-Anne-de-Beaupré, (Québec) 22-09-72 Région de Montréal \u2014 Montreal Region Jacques, Elphège, 188 est, rue Principale, Farnham, Missisquoi, (Québec) 15-09-72 Jacques, Paul-Léon, 188 est, rue Principale, Farnham, Missisquoi, (Québec) 15-09-72 Moisan, Maurice, 3477, Drummond, App.503, Montréal 107, (Québec) 05-01-73 Podlog, Charles, 531, Abercorn, Ville Mont-Royal, Montréal 305, (Québec) 15-03-73 Venne, Rosario, St-Hippolyte, Terrebonne, (Québec) 04-04-73 Région du Saguenay, Lac St-Jean \u2014 Saguenay, Lake St-John Region Tremblay, Jean-Marie, Case postale 40, Sacré-Coeur-de-Jésus, Saguenay, (Québec) 05-10-72 Région du Nord-Ouest \u2014 North West Region Morin, Léo-Paul, Case postale 570, rue Notre-Dame de Lourdes, Ville-Marie, 01-10-72 Témiscamingue, (Québec) Surkis, Max, 68, avenue des Pins, Lebel-sur-Quévillon, Abitibi, (Québec) 16-11-72 56260-o 1734 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March Z, 1974, Vol.106, No.9 Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions LA CAISSE POPULAIRE DE BEEBE (Loi des causes d'épargne cl de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 22 novembre 1973 par « LA CAISSE POPULAIRE DE STE-THERESE DE L'E.-J.DE BEEBE », changeant son nom en celui de « LA CAISSE POPULAIRE DE BEEBE », Québec, le 30 janvier 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 56245-0 Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DE BEEBE (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bvlaw adopted on November 22, 1973, by \"LA CAISSE POPULAIRE DE STE-THERESE DE L'E.-J.DE BEEBE\" changing its name to that of \"LA CAISSE POPULAIRE DE BEEBE\".Québec, January 30, 1974.56245 Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses PETER'S BAG CORPORATION Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « PETER'S BAG CORPORATION » a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.James A.Robb, de Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est situé au numéro 1155, boulevard Dorchester ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.5615S PA: 48-73 PETER'S BAG CORPORATION Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"PETER'S BAG CORPORATION\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.James A.Robb, of Montreal.The principal office of the company in the Province is at 1155 Dorchester Boulevard West, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.56158-0 PA: 48-73 WESTERN REALTY SHOPPING CENTRES LTD.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « WESTERN REALTY SHOPPING CENTRES LTD.> a été autorisée à exercer son commerce dans la province .L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Michael Vineber, édifice de la Banque Royale du Canada, 1, Place Ville Marie, Montréal.Le bureau principal de la compagnie est situé dans l'édifice de la Banque Royale du Canada, 1, Place Ville Marie, Montréal, district judiciaire de Montréal.ht sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.56158 PA: 24-73 WESTERN REALTY SHOPPING CENTRES LTD.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"WESTERN REALTY SHOPPING CENTRES LTD.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Michael Vincber, The Royal Bank of Canada Building, 1 Place Ville Marie, Montreal.The principal office of the company in the Province is at The Royal Bank of Canada Building.1 Place Ville Marie, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.56158-o PA: 24-73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1974, 10C' année, n\" 9 1735 Changement de nom \u2014 Loi du Change of name \u2014 Act Demandes Applications Katherine McNutt Avis est par les présentes donné que Katherine McNutt, domiciliée au 599, Blough, Arvida, district de Chicoutimi, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption d'un décret pour changer son nom à « Katherine Hrycko ».Ce changement n'affectera aucune autre personne que la requérante elle-même.Arvida, le 11 février 1974.Les procureurs de la requérante, 56084-8-2-o Tremblay & Tremblay, avocats.Katherine McNutt Notice is hereby given that Katherine McNutt residing at 599, Blough Street, Arvida, district of Chicoutimi, will petition the Lieutenant-Governor in Council for permission to change her name to \"Katherine Hrycko\".This change will not affect any person else than the applicant.Arvida, February 11th, 1974.Tremblay & Tremblay.Lawyers, 56084-8-2-o Attorneys for applicant.Marcil Pierre Bouliane Avis est donné que Marcil Pierre Bouliane, étudiant, domicilié et résidant au 4200 Grand Boulevard à Montréal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec afin de changer son nom en celui de Peter Bouliane.56140-8-2-o Arthur Lamoureux Avis est par les présentes donné que Arthur Sauve, domicilié au 11964 rue Matte, app.6, ville de Montréal-nord, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Arthur Lamoureux.Montréal, le 12 février 1974.Les avocats, 56107-8-2-o Druker & Freed.Marcil Pierre Bouliane Notice is hereby given that Marcil Pierre Bouliane, student, domiciled and residing at 4200 Grand Boulevard in Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the purpose of having his name changed to Peter Bouliane.56140-8-2-o Arthur Lamoureux Notice is hereby given that Arthur Sauvé, of the City of Montreal north, District of Montreal, domiciled at 11964 Matte St., Apt.6, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the adoption of a decree changing his name to Arthur Lamoureux.Montreal, February 12, 1974.Druker & Freed, 56107-8-2-o Advocates.Leo Darcatch Avis est, par les présentes, donné que Leo Darcatch, de la cité de Acapulco, Mexico, et demeurant à 10 Monterry Avenue, adresse une requête au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec pour l'autoriser à changer son nom de famille, de Darcatch à Bercovitch.Montréal, 13 février 1974.Les procureurs de requérant, Robinson, Sheppard, Borenstein, 56124-8-2-0 Shapiro & Flam.Leo Darcatch Notice is given that Leo Darcatch, of the City of Acapulco, Mexico, therein residing at 10 Monterry Avenue, is making application to the Lieutenant-Governor in Council for the Province of Québec for authorization to change his surname from Darcatch to Bercovitch.Montreal, February 13th, 1974.Robinson, Sheppard.Borenstein, Shapiro & Flam, 56124-8-2-0 Attorneys for petitioner.Yvon Décarie Avis est donné que Yvon Décarie, organisateur pour un tournoi d'échecs, époux de Ginette Cloutier, résidant et domicilié au 8327, rue Boyce, Montréal, district de Montréal, s'adressera au ministre de la justice de la province de Québec, en vue d'obtenir du lieutenant-gouverneur en conseil un décret changeant son nom en celui de Yvon Berger.Montréal, ce 30 janvier 1974.Les procureurs du requérant, Johanne Gagnon Trudel, Robert, 56153-8-2-0 Lavoie & Hargreaves.Yvon Décarie Notice is hereby given that Yvon Décarie, organizer for a chess tournament, husband of Ginette Cloutier, residing and domiciled at 8327 Boyce Street, Montreal, district of Montreal, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec, for a decree of the Lieutenant-Governor in Council, changing his name to Yvon Berger.Montreal, January 30, 1974.Johanne Gagnon Trudel, Robert, Lavoie & Hargreaves, 56153-8-2-0 Attorneys for the Petitioner. 1736 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974.Vol.106.No.9 Patricia Bryson Prenez avis que mademoiselle Patricia Bryson, domiciliée au 391 rue St-Joseph, Lauzon, présentera une demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour que son nom de famille soit changé pour le nom de « Carrier ».Les -procureurs de la requérante.56106-8-2-o Turgeon & Brodeur, avocats.Jan Jech Avis est donné que Jan Jech, étudiant, domicilié et résidant au 4992 avenue Trenholme à Montréal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin de changer son nom en celui de Jan Jech Marek.56141-8-2-0 Marie Anna Adélaïde Laionde Avis est par la présente donné que Marie Anna Adélaïde Laionde, ménagère, résidante et domiciliée au 1053, rue St-Jean, à Chambly, district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil d'adopter officiellement le nom de Germaine Fortier.Longueuil, le 23 janvier 1974.Les procureurs de la requérante.Pilon, Ferrari, 56194-9-2-0 Braconnier.Larivière.George Hector Boynton Brosseau Avis est par les présentes donné que George Hector Boynton Brosseau, superviseur, domicilié au 175 boul.DeGuire, app.1402, dans les ville et district de Mont-tréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de George Hector Boynton et changeant le nom de son épouse, Dame Christine Anne Brosseau, domiciliée à l'adresse susmentionnée en celui de Dame Christine Anne Boynton.Montréal, ce 13e jour de février, 1974.Les avocats des requérantes, Duquet, Mackay.Weloon, 56239-9-2-0 Bronstetter & Thivierge.George Kenneth Boynton Brosseau Avis est par les présentes donné que George Kenneth Boynton Brosseau, opérateur, domicilié au 2441 Grand Trunk Street, dans les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Kenneth Frederick Boynton et changeant le nom de son épouse.Dame Rita Alexina Brosseau domiciliée à l'adresse susmentionnée en celui de Rita Alexina Boynton.Montréal, ce 13e jour de février, 1974.Les avocats des requérantes.Duquet, Mackay.Weldon, 56240-9-2-o Bronstetter & Thivierge.Patricia Bryson Notice is given that Miss Patricia Bryson, domiciled at 391 St.Joseph Street, Lauzon, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing her family name to \"Carrier\".Turgeon & Brodeur, Lawyers, 56106 8-2-o Attorneys for the Petitioner.Jan Jech Notice is hereby given that Jan Jech, student, residing and domiciled at 4992 Trenholme Avenue in Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the purpose of having his name changed to Jan Jech Marek.56141-8-2-0 Marie Anna Adélaïde Laionde Notice is hereby given that Marie Anna Adélaïde Laionde, residing at 1053, St-Jean, in Chambly, District of Montreal, will make application to the Lieutenant-Governor in council to have her name changed to Germaine Fortier.Longueuil, this January 23.1974.Pilon, Ferrari, Braconnier, Larivière, 56194-9-2-o Attorneys for Pétitionner.George Hector Boynton Brosseau Notice is given that George Hector Boynton Brosseau, supervisor, domiciled at 175 DeGuire Blvd., Apt.1402.in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the granting of an order changing his name to that of George Hector Boynton.and changing the name of his wife Dame Christine Anne Brosseau, domiciled at the same address to that of Dame Christine Anne Boynton.Montreal, this 13th day of February, 1974.Duquet, Mackay, Weldon, Bronstetter & Thivierge, 56239-9-2-0 Attorneys for Applicants.George Kenneth Boynton Brosseau Notice is hereby given that George Kenneth Boynton Brosseau, operator, domiciled at 2441 Grand Trunk Street in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the granting of an order changing his name to that of Kenneth Frederick Boynton, and changing the name of his wife, Dame Rita Alexina Brosseau domiciled at the same address, to that of Rita Alexina Boynton.Montreal, this 13th day of February, 1974.Duquet, Mackay, Weldon, Bronstetter & Thivierge, 56240-9-2-o Attorneys for Applicants. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1974, 106' année, n\" 9 1737 Marie Régina Yvette Violette Taylor Winibrd Avis est donné par les présentes que Marie Régina Yvette Violette Taylor Winford, ménagère, de 2259 avenue Madison, Montréal, entend présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil demandant le changement de son nom à Mary Jo Holland Winford, conformément aux dispositions de la Loi du changement du nom.Montréal, le 7 janvier 1974.Le procureur de la requérante, 56195-9-2-0 Me Warren Baer.Robert Roy Avis est par les présentes donné que Robert Roy, résidant et domicilié au 87 A, Des Laurentides, Ville de Laval, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, pour obtenir un décret changeant son nom de Robert Roy en celui de Robert Frederic de Monsroy.Montréal, ce 14 février 1974.Les procureurs du requérant.Mes Shadley, 56196-9-2-o Melançon & Ass., avocats.Lise Martel Avis est par les présentes donné que, Lise Martel, domiciliée au 366, rue Gélinas, app.2, Cap-de-la-Madeleine, présentera une requête au ministre de la justice, pour changer son nom en celui de Lise St-Pierre.Ce changement n'affectera aucune autre personne que la requérante elle-même.Trois-Rivières, le 2 mars 1974.Les procureurs de la requérante, 56241-9-2-0 Martin & Blais, notaires.Corinne Jeanne Ashton Corinne Jeanne Ashton, généralement connue sous le nom de Corinne Jeanne Samson, serveuse, de la ville de Candiac, district de Montréal, où elle est domiciliée et demeurant au numéro 55, avenue Hermes.Avis est donné par les présentes que Corinne Jeanne Ashton s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin de changer son nom de Corinne Jeanne Ashton en celui de Corinne Jeanne Samson.Le 7 février 1974.Le procureur de la requérante, 56261-9-2 Me Robert G.Wolfe, avocat.Mark Brian Epstein Avis est par les présentes donné que Mark Brian Epstein, résidant et domicilié au 5717 Wentworth, Côte St-Luc, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, pour un décret changeant son nom de Mark Brian Epstein à celui de Mark Brian Epstein Singer.Montréal, ce 19 février 1974.Les avocats, 56264-9-2-0 Mes Rothman & Rubin.Marie Régina Yvette Violette Taylor Winford Notice is hereby given that Marie Régina Yvette Violette Taylor Winford, housewife, domiciled at 2259 Madison Avenue, Montreal, intends to present a petition to the Lieutenant-Governor in Council requesting the change of her name to Mary Jo Holland Winford, pursuant to the provisions of the Change of Name Act.Montreal, January 7th.1974.Mtre.Warren Baer, 56195-9-2-o Attorney for Petitioner.Robert Roy Take notice that Robert Roy, residing and domiciled at 87 A, Des Laurentides Blvd., City of Laval, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from Robert Roy to Robert Frederic de Monsroy.Montreal, February 14, 1974.Mes Shadley.Melançon & Ass., lawyers, 56196-9-2-0 Attorneys for the Petitioner.Lise Martel Notice is hereby given that Lise Martel domiciled at 366 Gélinas, Appt.2, Cap-de-la-Madeleine, will present a petition to the Minister of Justice in order to change her name to that of Lise St-Pierre.This change will not affect any person else than the applicant.Trois-Rivières, March 2, 1974.Martin & Blais, Notaries, 56241-9-2-o Attorneys for the Applicants.Corinne Jeanne Ashton Corinne Jeanne Ashton, publicly known as Corinne Jeanne Samson, waitress, of the Town of Candiac, District of Montreal, therein domiciled and residing at 55 Hermes Avenue.Notice is hereby given that Corinne Jeanne Ashton will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have her name changed from Corinne Jeanne Ashton to Corinne Jeanne Samson.February 7th, 1974.Mtre Robert G.Wolfe, advocate.56261-9-2-o Attorney for the Pelitioner.Mark Brian Epstein Notice is hereby given that Mark Brian Epstein, residing and domiciled at 5717 Wentworth, Côte St.Luc, district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from Mark Brian Epstein to Mark Brian Epstein Singer.Montreal, February the 19th, 1974.Mes Rothman & Rubin, 56264-9-2-0 Lawyers. 1738 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.b Julius Cappel Avis est par la présente donné que Julius Cappel, vendeur, résidant et domicilié au 400 avenue Lans-downe, ville de Westmount, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Quél>ec, un décret changeant son nom en celui de Julius Cappell, duquel changement bénéficiera aussi son épouse, Mildred Cappel, domiciliée à l'adresse ci-haut mentionnée.Montréal, 22 février 1974.Les procureurs du requérant, Greenblatt, Godinskv, Resin 56262-9-2-0 & Uditskv.Joseph Mastaï Jean Luc Coutu Avis est par les présentes, donné selon l'article 5, Loi du changement de nom, que Joseph Mastaï Jean Luc Coutu, officier d'immigration, demeurant et domicilié au No 1160 rue Alexandre De Sève, apt.2, en les cité et district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption d'un décret changeant son nom à Joseph Mastaï Jean Luc Coutu de Lavaltrie.Le changement de son nom bénéficiera aussi à sa femme, de la même adresse.Montréal, le 20 février 1974.Les procureurs du requérant, 56263-9-2-0 Bélanger & Blais.Fikin Leon Sabbag Avis est donné que Fikin Léon Sabbag, commerçant, demeurant au 70 boul.Crépeau, ville St-Laurent, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Viken Léon Sabbaghian.Montréal, le 20 février 1974.Les procureurs du requérant, 56265-9-2-o Awada, Gareau & Sumbulian.Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Diane Binette Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 510 du 13 février 1974 d'effectuer le changement de nom de Marie Diane Jacqueline Colette Couture en celui de Diane Binette.Québec, le 21 février 1974.Julius Cappel Notice is hereby given that Julius Cappel, salesman, residing and domiciled at 400 Lansdowne Avenue, Westmount, Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec, for an order changing his name to Julius Cappell, which change will also benefit his wife, Mildred Cappel, residing and domiciled at the address mentioned above.Montreal, February 22nd, 1974.Greenblatt, Godinsky, Resin & Uditsky, 56262-9-2-0 Attorneys for A pplicant.Joseph Mastaï Jean Luc Coutu Notice is hereby given pursuant to section 5 of the Change of Name Act that Joseph Mastaï Jean Luc Coutu.immigration officer, residing and domiciled at 1160 Alexandre de Sève, No.2, in the City and district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for the adoption of an order changing his name to Joseph Mastaï Jean Luc Coutu de Lavaltrie.The change of name shall benefit his wife of same address.Montreal, February 20, 1974.Bélanger & Blais, 56263-9-2-0 Attorneys for the A pplicant.Fikin Leon Sabbag Notice is hereby given that Fikin Léon Sabbag, Businessman, residing at 70 Crépeau Blvd., Ville St.Laurent, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the adoption of an order changing his name to that of Viken Léon Sabbaghian.Montreal.February 20.1974.Awada, Gareai\" & Sumbulian, 56265-9-2-q Attorneys for Petitioner.Change of name \u2014 Act Granted Diane Binette It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Diane Jacqueline Colette Couture to that of Diane Binette by order number 510, dated February 13, 1974.Québec, February 21, 1974.Le sous-ministre de la justice.Robert Normand, q.c, 56162-0 Robert Normand, c.r.56162 Deputy Minister of Justice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n\" 9 1739 Anthony Chapatis Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 505 du 13 février 1974 d'effectuer le changement de nom de Anthony (Antonius) Czepaitis en celui de Anthony Chapatis.Québec, le 21 février 1974.Le sous-ministre de la justice, 56162-o Robert Normand, c.r.Bronnie Chapatis Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 506 du 13 février 1974 d'effectuer le changement de nom de Brenislaus Czepaiies en celui de Bronnie Chapatis.Québec, le 21 février 1974.Le sous-ministre de la justice, 56162-0 Robert Normand, c.r.John Anthony Chapatis Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 507 du 13 février 1974 d'effectuer le changement de nom de John Anthony Chapates en celui de John Anthony Chapatis.Québec, le 21 février 1974.Le sous-ministre de la justice, 56162-0 Robert Normand, c.r.Walter Michael Chapatis Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 508 du 13 février 1974 d'effectuer le changement de nom de Walter Michael Chapates en celui de Walter Michael Chapatis.Québec, le 21 février 1974.56162-0 Le sous-ministre de la justice, Robert Normand, c.r.Jeanne Côté Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 509 du 13 février 1974 d'effectuer le changement de nom de Marie Odile Côté en celui de Jeanne Côté.Québec, le 21 février 1974.Le sous-ministre de la justice, 56162-0 Robert Normand, c.r.Anthony Chapatis It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Anthony (Antonius) Czepaitis to that of Anthony Chapatis by order number 505, dated February 13, 1974.Québec, February 21, 1974.56162 Robert Normand, q.c.Deputy Minister of Justice.Bronnie Chapatis It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Brenislaus Czepaiies to that of Bronnie Chapatis by order number 506, dated February 13, 1974.Québec, February 21, 1974.Robert Normand, q.c, 56162 Deputy M in ister of J ustice.John Anthony Chapatis It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of John Anthony Chapates to that of John Anthony Chapatis by order number 507, dated February 13, 1974.Québec.February 21, 1974.-.6162 Robert Normand, q.c, Deputy Minister of Justice.Walter Michael Chapatis It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Walter Michael Chapates to that of Walter Michael Chapatis bv order number 508, dated February 13, 1974.Québec, February 21, 1974.56162 Robert Normand, q.c.Deputy Minister of Justice.Jeanne Côté It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Odile Côté to that of Jeanne Côté by order number 509, dated February 13, 1974.Québec, February 21, 1974.Robert Normand, q.c, 56162 Deputy Minister of Justice.Marian Gordon Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 513 du 13 février 1974 d'effectuer le changement de nom de Marian Gedziorowski en celui de Marian Gordon.Québec, le 21 février 1974.Le sous-ministre de la justice, 56162-o Robert Normand, c.r.Marian Gordon It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marian Gedziorowski to that of Marian Gordon by order number 513, dated February 13, 1974.Québec, February 21, 1974.Robert Normand, q.c, 56162 Deputy Minister of Justice. 1740 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March S, 1974.Vol.106, No.9 Jack Albert Hillrich Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 511 du 13 février 1974 d'effectuer le changement de nom de Jack Albert Smith en celui de Jack Albert Hillrich.Québec, le 21 février 1974.Le sous-ministre de la justice, 56162-0 Robert Normand, c.r.Abraham Kirsch Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 512 du 13 février 1974 d'effectuer le changement de nom de Abraham Kirschenzaft en celui de Abraham Kirsch.Québec, le 21 février 1974.Le sous-ministre de la justice.56162-0 Robert Normand, c.r.Stanley Lonn Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 514 du 13 février 1974 d'effectuer le changement de nom de Stanley Reinblatt en celui de Stanley Lonn.Québec, le 21 février 1974.Le sous-ministre de la justice, 56162-o Robert Normand, c.r.Irving Mazer Miller Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 515 du 13 février 1974 d'effectuer le changement de nom de Irving Mazer en celui de Irving Mazer Miller.Québec, le 21 février 1974.Le sous-ministre de la justice, 56162-o Robert Normand, c.r.Jack Albert Hillrich It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Jack Albert Smith to that of Jack Albert Hillrich by order number 511, dated February 13, 1974.Québec, February 21, 1974.Robert Normand, q.c, 56162 Deputy Minister of Justice.Abraham Kirsch It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Abraham Kirschenzaft to that of Abraham Kirsch by order number 512, dated February 13, 1974.Québec.February 21, 1974.Robert Normand, q.c, 56162 Deputy Minister of Justice.Stanley Lonn It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Stanley Reinblatt to that of Stanley Lonn by order number 514, dated February 13, 1974.Québec, February 21, 1974.Robert Normand, q.c, 56162 Deputy Minister of Justice.Irving Mazer Miller It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Irving Mazer to that of Irving Mazer Miller by order number 515, dated February 13.1974.Québec, February 21, 1974.Robert Normand, q.c, 56162 Deputy MinLiter of Justice.Demandes à la Législature Applications to Legislature EATON REGULAR BAPTIST CHURCH Avis est par les présentes donné que Elwood Rolles-ton, employé du téléphone, r.r.2, Magog, Québec; James French, retraité, Sawyerville.Québec; et Robert Taylor, agriculteur, r.r.3, Sawyerville, Québec; adresseront une requête au Lieutenant Gouverneur en Conseil afin d'obtenir la constitution en corporation de « EATON REGULAR BAPTIST CHURCH », conformément aux dispositions de la Loi de la constitution de certaines Églises, chapitre 305, Statuts Refondus du Québec de 1964.Eaton, (Québec), 29 janvier 1974.Le procureur des requérants.56022-7-4 Harrt E.Grundy, c.r.EATON REGULAR BAPTIST CHURCH Notice is hereby given that Elwood Rolleston, telephone employee, R.R.2.Magog, Québec; James French, retired, Sawyerville, Québec; and Robert Taylor, farmer, R.R.3, Sawyerville, Québec; will apply by Petition to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Quelle, for incorporation of the \"EATON REGULAR BAPTIST CHURCH\" under the provisions of the Church Incorporation Act, Chapter 305, Revised Statutes of Québec 1964.Eaton, Québec, January 29th 1974.Harry E.Grundy, q.c.56022-7-4-o Attorney for Petitioners. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1974, 106< année, n° 9 1741 LA COMMUNAUTE URBAINE DE QUEBEC Avis est par les présentes donné que la Communauté urbaine de Québec s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec, au cours de la présente session, pour demander l'adoption d'une loi amendant sa loi constitutive pour en modifier les annexes, et entre autres dispositions, les définitions, la façon générale d'exercer ses pouvoirs, la procédure de mise en candidature à la charge de membre du comité exécutif, la durée des mandats et la procédure permettant de combler les vacances, la participation de la Communauté au paiement d'une partie de la pension du président du comité exécutif, les pouvoirs du comité exécutif, la composition du Conseil, la procédure de fixation de la date des assemblées du Conseil et la procédure de convocation, le calcul de la rémunération des membres du Conseil, la procédure de votation aux commissions du Conseil, les devoirs du secrétaire, les pouvoirs et la compétence de la Communauté, la procédure d'appel d'offres, les dispositions ayant trait à l'évaluation foncière, les titres de la Communauté sur ses terrains industriels, la procédure de disposition d'immeubles, certaines dispositions financières relatives aux emprunts et aux garanties, certaines dispositions concernant les modalités de perception de la répartition, certaines dispositions concernant le territoire périphérique, certaines dispositions concernant l'élaboration et la mise en oeuvre du schéma d'aménagement, le financement du BAEQM et de la CTCUQ.la répartition du déficit de la CTCUQ, ainsi que certaines dispositions financières et autres concernant la régie interne de la CTCUQ, et pour toute autre disposition.Québec, ce 00 février 1974.Les avocats, 56269-9-4-0 Y van Dallaire et Jacques Forgues.Assemblée nationale Canada Province de JEAN TURGEOX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À nos très aimés et fidèles conseillers les membres de l'Assemblée nationale du Québec, Salut.Proclamation Attendu que, pour diverses considérations, il est à propos de convoquer la Législature de la province de Québec pour l'expédition des affaires, Nous vous convoquons par les présentes pour la quatorzième jour de mars prochain et, en conséquence, vous mandons et ordonnons de vous assembler à cette date, au palais QUEBEC URBAN COMMUNITY Notice is hereby given that the Québec Urban Community will petition the National Assembly of the Province of Québec, at is present session, to modify it's schedules and the dispositions of its constitutive law, among others, to wit: the definitions, the general exercise of its powers, the procedure of nomination as a candidate for the Executive Committee, the term of office, the filling up procedure of vacancies, the Community's participation to the payment of a part of the Executive Committee Chairman's pension plan, the Executive Committee's powers, the composition of the Council, the procedure to determine the Council's meeting's date and convocations' procedure, the computation of the Council's members' remuneration, the voting procedure at the committees of the Council, the secretary's duties, the powers and competence of the Community, the calling for tenders' procedure, the real estate assessment's provisions, the titles of the Community on its industrial land, the procedure to dispose of its immoveables, some financial provisions relating to loans and guaranties, some provisions concerning collection of the apportionment of expenses, some provisions concerning the peripheral territory, some provisions concerning the preparation and the execution of the development plan, the GQWPB and QUCTC financing, the QUCTC deficit apportionment, and some financial provisions and other provisions pertaining to the QUCTC administration; and any other provisions.Québec, this February 00, 1974.Y van Dallaire and Jacques Forgues, 56269-9-4-0 lawyers.National Assembly Canada, Province of JEAN TURGEON Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To our Beloved and Faithful Councillors, the members of the National Assembly of Québec, Greeting.Proclamation Whereas, for various considerations, it is expedient to summon the Legislature of the Province of Québec for the dispatch of business, We hereby convene you for the fourteenth day of March next and, accordingly, command and order you to meet on such date at the Parliament Buildings, in the city of Québec, for the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol- 106, No.9 1742 législatif, en la ville de Québec, pour y expédier les affaires de la province et y examiner, discuter et décider les questions qui vous seront soumises.En foi de quoi.Nous avons fait rendre nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de la province de Québec.Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Juge Jean Turgeon, administrateur du gouvernement de ladite Province.Donné en Notre hôtel du gouvernement, à Québec, le vingt et unième jour de.février, l'an de grâce mil neuf cent soixante-quatorze et de Notre règne le vingt-troisième.Par ordre.Le secrétaire de la chancellerie à Québec, 56198-9-x-o René Blondin.Concernant les projets de loi privés qui seront présentés pendant la prochaine session.Conformément aux règles de pratique adoptées par l'Assemblée nationale le 21 décembre 1972 et dont un exemplaire peut être obtenu en s'adressant au soussigné: Les projets de loi privés doivent être déposés au secrétariat des commissions avant le jour de l'ouverture de la session.Les documents dont il est fait mention dans le projet doivent être déposés avec celui-ci.Québec, le 21 février 1974.Le secrétaire des commissions.56198-9-x-o Jacques Pouliot.Nominations Avis est donné qu'il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil de faire, par commission sous le grand sceau de la province, la nomination suivante: Québec, le 6 février 1974.M.Gérald Boisvert, 3154, rue Denonville, Sainte-Foy, Québec 10, juge de la Cour provinciale jusqu'au 5 février 1974 inclusivement, nommé en vertu de l'article 72 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 20 et ses amendements), juge des sessions avec juridiction dans toute la province mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec; ledit M.Gérald Bois-vert, juge des sessions, étant autorisé à exercer sous l'autorité du paragraphe b de l'article 482 du Code criminel, la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, le tout à compter du 6 février 1974.Québec, le 19 février 1974.Le sous-procureur général adjoint, 56162-0 René Langevin.dispatch of the business of the Province and to examine, discuss and decide the questions to be submitted to you.In testimony whereof.We have caused these Our letters to be made patent and the Great Seal of our Province of Québec to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable Justice Jean Turgeon, Administrator of the Government of the said Province.Given at Our Government House, in Québec, on the twenty-first day of February, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and seventy-four, in the twenty-third year of Our Reign.By command, René Blondin.56198-9-x-o Clerk of the Croum in Chancery, at Québec.Concerning private bills which shall be introduced during the next session.In accordance with the rules of procedure adopted by the National Assembly on December 21st 1972, a copy of which may be obtained from the undersigned: Private bills shall be filed with the Secretariat of Committees before the day of the opening of the session.The documents mentioned in the bill must be filed with it.Québec, February 21st 1974.Jacques Pouliot, 56198-9-x-o Secretary of Committees.Appointments Notice is given that the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to make the following appointment by commission under the Great Seal of the Province: Québec, February 6, 1974.Mr.Gérald Boisvert, 2154 Denonville Street, Ste.Foy, Québec, Judge of the Provincial Court until February 5, 1974 inclusive, appointed under section 72 of the Courts of Justice Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 20 and Amendments), Judge of the Sessions with jurisdiction in the entire Province, but particularly and without restriction in the Judicial District of Québec; the said Mr.Gerald Boisvert, Judge of the Sessions, being empowered to exercise, under paragraph 6 of section 482 of the Criminal Code, the jurisdiction of Magistrate under Part XVI of said Criminal Code, the foregoing to take effect from February 6, 1974.Québec, February 19, 1974.René Langevin, 56162 Assistant Deputy Attorney General. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n° 9 1743 Avis est donné qu'il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil de faire, par commission sous le grand sceau de la province, la nomination suivante: Québec, le 16 janvier 1974.Me Roch Héroux, avocat, substitut du procureur général, classe senior: coroner pour le district judiciaire de Montréal, et ce, à compter du 16 janvier 1974.Québec, le 21 février 1974.Le sous-procureur général adjoint, 56162-o René Langevin.Ministère des affaires municipales Bureau de revision du district de Québec Conformément à l'article 44 de la Loi sur l'évaluation foncière, j'ordonne que les limites du territoire du district de revision de Québec du Bureau de revision de l'évaluation foncière du Québec soient modifiées pour y inclure le territoire de la cité des Sept-îles.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Québec, le 11 février 1974.Le ministre des affaires municipales, 56205-o Victor C.Goldbloom.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Assurances GAMBLE ALDEN LIFE INSURANCE COMPANY Avis de fusion Avis est donné par les présentes que « GAMBLE ALDEN LIFE INSURANCE COMPANY » dont le siège social est situé à Chicago, Illinois, États-Unis d'Amérique, et « GAMBLE ALDEN LIFE INSURANCE COMPANY » dont le siège social est situé à St.Louis Park, Minnesota, États-Unis d'Amérique, lesquelles compagnies étaient dûment autorisées à faire affaires dans le Québec, se sont fusionnées en une seule compagnie sous le nom de « GAMBLE ALDEN LIFE INSURANCE COMPANY », en vertu d'un contrat de fusion intervenu entre ces deux compagnies le 8 juin 1973, lequel contrat de fusion a pris effet le 31 décembre 1973.Donné à Winnipeg, Manitoba, le 3e jour de janvier 1974.lie vice-président et agent principal, 56270-9-2-o William R.Templin.Notice is given that the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to make the following appointment by commission under the Great Seal of the Province: Québec.January 16, 1974.Me.Roch Héroux, lawyer, Deputy Attorney General, senior class: Coroner for the Judicial District of Montreal, the foregoing to take effect from January 16, 1974.Québec, February 21, 1974.René Langevin, 56162 Assistant Deputy Attorney General.Department of Municipal Affairs Board of Revision for the District of Québec Pursuant to section 44 of the Real Estate Assessment Act, I hereby order that the limits of the territory of the Québec District of the Québec Real Estate Assessment Board of Revision be modified to include the territory of the City of Sept-îles.The present order shall come into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Québec, February 11, 1974.Victor C.Goldbloom.56205 Minister of Municipal Affairs.Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Insurance GAMBLE ALDEN LIFE INSURANCE COMPANY Notice of merger Notice is hereby given that \"GAMBLE ALDEN LIFE INSURANCE COMPANY\" whose head office is situated at Chicago Illinois.United States of America, and \"GAMBLE ALDEN LIFE INSURANCE COMPANY\" whose head office is situated at St.Louis Park, Minnesota, United States of America, which companies were duly authorized to do business in Québec, have merged into only one company under the name of \"GAMBLE ALDEN LITE INSURANCE COMPANY\" according to an agreement of merger entered into by these two companies on the 8th of June 1973, with effect from the 31st of December 1973.Given at Winnipeg, Manitoba, this 3rd day of January 1974.William R.Templin, 56270-9-2-o Vice-President and Chief Agent. 1744 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.9 GRAIN INSURANCE AND GUARANTEE COMPANY Avis d'émission de permis el de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que « GRAIN INSURANCE AND GUARANTEE COMPANY», enregistrée sous le numéro 758 a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 1784 qui l'autorise à compter du 7 janvier 1974, à effectuer dans la province des contrats relatifs aux genres d'assurance suivants: incendie, et accessoirement \u2014 agitation civile, choc de véhicules, chutes d'aéronef, défectuosité d'extincteurs automatiques, fuite d'eau, grêle, ouragan; accident; biens immobiliers; biens mobiliers; bris de glace; bris de machine; chaudière à vapeur; explosion; faux; garanties; intempéries; transport intérieur; tremblement de terre; vol.Le siège social de la compagnie est situé à 167, avenue Lombard, Winnipeg, Manitoba.La compagnie a nommé monsieur Eric Lee Cleik, 360 ouest, lue St-Jacques, Montréal, son procureur dans la province.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 20 février 1974.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Prorince, Le Surintendant des assurances, 56249-9-2-0 Roger-A.Camaraire.LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES, COMTE DE SAINT-HYACINTHE Avis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Attendu que « LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES, COMTE DE SAINT-HYA- (TNTIIK a (-,\u2022-.(¦ de faire affaires dans le Québec le 13 mai 1973; Attendu que le président et le secrétaire-trésorier de ladite compagnie ont produit au Service des assurances, le 24 septembre 1973, une déclaration assermentée à l'effet que la compagnie a annulé toutes ses polices, payé toutes ses dettes et distribué son surplus; En conséquence, avis est par les présentes donné que les permis et certificat d'enregistrement de « LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES.COMTE DE SAINT-HYACINTHE» sont annulés à compter du 24 septembre 1973.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 31 décembre 1973.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province, Le Surintendant des assurances.56154-8-2-o Rocer-A.Camaraire.GRAIN INSURANCE AND GUARANTEE COMPANY Notice of Issue of License and Certificate of Registration Notice is herebv given that \"GRAIN INSURANCE AND GUARANTEE COMPANY\", registered undei number 758, has obtained the license and certificate of registry number 1784, authorizing it, as from the 7th of January 1974, to undertake in the Province contracts of insurance in the following classes: Fire, and supplementary thereto \u2014 civil commotion, falling aircraft, hail, impact by vehicles, spinkler leakage, water damage, windstorm; accident; boiler; Earthquake; Explosion, Forgery, Guarantee, Inland transportation: Machinery; Personal property; Plate glass; Real property; Theft; Weather.The head office of the company is situated at 167 Lombard Avenue, Winnipeg, Manitoba.The company has appointed Mr.Eric Lee Clark, 360 St.James Street West, Montreal, its attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 20tb of February 1974.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger A.Camaraire, 56249-9-2-o Superintendent of Insurance.LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES, COMTE DE SAINT-HYACINTHE Notice of Cancellation of Licence and Certificate of Registration Whereas the \"LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES.COMTE DE SAINT-HYACINTHE\" has ceased to do business in Québec as from the 13th of May 1973; Whereas the president and the secretary-treasurer of the said company have filed, on the 24th of September, 1973.with the Insurance Branch, a sworn declaration to the effect that the company had cancelled all its policies, discharged all its debts and distributed its surplus; Therefore, notice is hereby given that the licence and certificate of registration of the \"LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES.COMTE DE SAINT-HYACINTHE\" are cancelled as from the 24th of September 1973.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, the 31st of December 1973.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger A.Camaraire, 56154-8-2-0 Superintendent of Insurance. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1974, 106' année, n° 9 1745 Syndicats professionnels Professional Syndicates LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT DE LA REGION DE VALLEYFIELD (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, en vertu de l'article 25 de la Loi des syndicats professionnels, décrète la fin de l'existence corporative de «LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT DE LA REGION DE VALLEYFIELD ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.56246-0 SP: 1917-52 LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT DE LA REGION DE VALLEYFIELD (Professional Syndicales Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, pursuant to section 25 of the Professional Syndicates Act, has ordered the termination of the cooperative existence of \"LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT DE LA REGION DE VALLEYFIELD\".Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.56246 SP: 1917-52 Ventes pour taxes Sales for taxes Ville de Senneterre Avis public est par la présente donné que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique à l'Hôtel de Ville, situé au 551.10e Avenue à Senneterre, MARDI le DIX-NEUVIÈME jour du mois de MARS 1974 à DIX heures A.M.pour satisfaire au paiement des taxes municipales, des intérêts plus les frais encourus ou qui pourront être encourus à moins que ses taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.Le prix d'adjudication de chacune de ces propriétés sera payable immédiatement en monnaie légale ou par chèque visé.Town of Senneterre Public notice is hereby given that the properties described hereinunder will be sold by public auction in the Town Hall, situated at 551 - 10th Avenue, in Senneterre, on TUESDAY, the NINETEENTH day of MARCH 1974 at TEN o'clock A.M., to meet the payment of municipal taxes, interests, plus the costs which have been or may be incurred, unless the said taxes, interests and costs be paid before the sale.The adjudication price for each of said properties shall be payable immediately in legal currency or by certified cheque.Fiches Files Noms Xames Cadastre Cadastre Taxes munie.Munie, taxes.Intérêts Interests 4-18 Mme Germain Trottier 4-19 Mme Germain Trottier.4-37 M.Joseph Gagné.4-39 M.Joseph Gagné.4-41 M.Joseph Gagné.5-10 Mme Jeanne-d'Arc Lebel.6-27 et 27-1 Auto Confort Inc.10-14 M.Jean-Paul Meilleur.10-20 M.Robert Bérubê.10-25 M.Arthur Laionde____ 10-37 M.Louis-Claude Gauthier.10-44 M.Aimé Gagné.Partie du lot 26.Rang 7.Part of lot 26, Range 7.Partie du lot 26, Rang 7.Part of lot 26.Range 7.Partie du lot 27, Rang 7.Part of lot 27.Range 7.Partie du lot 27, lot 28, Rang 7.Part of lot 27.lot 28, Range 7.Partie du lot 27, Rang 7.Part of lot 27.Range 7.Lot 28, Rg 8, Subdivision 35.Lot 28, Range 8, Subdivision 36.Bloc 34, Part du lot 14, 15 et 16.Block 34.Part of lots 14, 16 and 16.Bloc / Block 77, lot 5.Bloc/ Block 11.lot 4.Bloc / Block 5.lot 3.Bloc /Block 83, lot 3.Bloc / Block 78, lot 2.101.97\tS 5.71 333.45\t22.26 20.15\t1.36 79.15\t3.99 80.24\t5.41 337.25\t21.41 1,209.39\t128.23 66.39 327.53 206.59 123.60 169.92\t1.59 20.76 12.60 11.07 10.12 1746 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.March 2.1974.Vol 106, No.9 Fiches Files 19-5 19-14 21-18 21-62 22-15 22-17 22-45 22-55 22-85 22-87 22-101 22-114 22-117 23-40 23-41 23-75 26-9 26-16 26-31 27-39 27-40 27-41 27-70 27-102 28-52 Nom6 Xames Cadastre Cadastre Taxes munie.Munie, taxes Intérêts Interests Mme François Gagné M.Joseph Gagné.Bloc 35.partie du lot 4.Block 35.part of lot 4- ____ Partie du lot 27, Rang 7.Part of lot 27.Range 7.M.Roger Courtemanche.I.Bloc / Block A,lot 9.M.Gaston Bilodeau.Bloc / Block 34, ot 13.M.Eddy Vachon.Bloc / Block 11, lot 7.M.François Durocher.Bloc 12, lot 7 et partie 8.Block 12.lot 7 and part 8.M.Real Caron.Bloc / Block 32, lot 5 .M.Jacques Bellehumeur.Lot 28, Rg 8, Subdivision 67.Lot 28, Range 8, Subdivision 67.M.Jean-Noêl Grondin.Bloc / Block 4, lot 6.M.Eddy Vachon.Bloc / Block 4, lot 11.Nettoyeur Senneterre.Bloc / Block 14, lot 20.Plouffe & Rioux Inc.Bloc / Block 33.lot 14.Plouffe & Rioux Inc.Bloc / Block 33, lot 11.M.Eddv Vachon .Bloc / Block 10, lot 19.M.Guy Roby.Bloc / Block 10, lot 18.M.Réal Caron.Bloc / Block 32, lot 11 et/and 12 M.Réal Lacroix.Bloc 82, partie du lot 1.Block 82, part of lot 1.M.Yvon Taylor.Bloc / Block 82, lot 8.M.Gérard Villeneuve.Bloc / Block 76, lot 15.M.Salvator Caron.Bloc / Block 94, lot 4.M.Salvator Caron.Bloc / Block 94, lot 4.M.Salvator Caron.Bloc / Block 94, lot 5.M.Alexandre Parent.Bloc 83, partie du lot 6.Block 8S.part of lot 6.M.Bertrand Grandmaison.Bloc 80, lot 13, partie 2.Block 80.lot 13.part 2.M.Gaston Bilodeau.Partie du lot 28, Rang 8.Part of lot 28, Range 8.110.53\tS 10.84 421.64\t21.71 279.62 98.42 402.95 298.47\t29.97 10.17 25.56 17.45 436.69 194.93\t29.48 6.28 341.25 85.68 478.80 1,869.77 67.63 284.41 150.65 1,779.30 473.55\t23.03 11.99 71.45 78.66 15.52 16.46 4.49 49.99 30.61 140.15 128.17 387.44 171.38 42.18 126.98\t21.61 8.65 26.15 11.57 2.85 11.95 208.35\t12.71 96.18\t10.00 Donné à Senneterre ce quatorzième jour du mois de février mil neuf cent soixante et quatorze.56145-8-2-0 Le secrétaire-trésorier.Marcel Mirault.Given in Senneterre, this fourteenth day of the month of February one thousand nine hundred seventy-four.Marcel Mirault, 56145-8-2-0 Secretary-Treasurer.Ville de Granby Avis est par le présent donné par le soussigné.Donat Brosseau, greffier de la Ville de Granby.que l'immeuble ci-dessous désigné sera vendu à l'enchère en la salle du conseil de l'Hôtel de Ville sise au 87.rue Principale à Granby, MERCREDI, le TROISIÈME jourd'AVRIL 1974, à QUATORZE heures (deux heures de l'après-midi), pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, avec intérêts, pour les frais encourus ou qui pourront être encourus à moins que ces taxes, intérêts et dépenses ne soient payés avant la vente.City of Granby Public notice is hereby given by the undersigned Donat Brosseau, Clerk of the City of Granby, that the immoveable hereinafter described will be sold by public auction in the Council Meeting Room, in the City Hall located at 87 Principale Street, in Granhy, on WEDNESDAY, the THIRD day of APRIL, 1974, at TWO o'clock in the afternoon, to satisfy to the payment of the municipal and school taxes, together with interests and costs incurred or that may be incurred, unless said taxes, interests and costs are paid prior to the sale.Propriétaire Owner Hôtel Mont Shefford (1970) Limitée.Toute cette partie du lot huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre cent quatre-vingt-douze (Ptie 492-8) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du Village de Granby, située au nord-ouest du trottoir de la rue Désignation Numéros de cadastre Description Cadastral numbers 492-8 Ptie All of that part of lot number eight of the official subdivision of original lot number four hundred ninety-two (Pt 492-8) on the official plan and in the book of reference of the cadastre for the Village of Granby, said part being GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1974, 106' année, n° 9 1747 Propriétaire Owner Désignation Description Nunoros de cadastre Cadastral numbers St-Hubert, à Granby, P.Q., et comprise entre le prolongement de la limite nord-est du lot 492-3 et le prolongement de la limite sud-ouest du lot 492-2.located northwest of the sidewalk of St.Hubert Street, in Granby, P.Q., and comprised between the extension of the northeast limit of lot 492-3 and the extension of the southwest limit of lot 492-2.Hôtel Mont Shefford (1970) Limitée.Le lot numéro trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre cent quatre-vingt-douze (492-3) aux mêmes plan et livre de renvoi officiels.492-3 Lot number three of the official subdivision of original lot number four hundred ninety-two (492-3) on said official plan and in said book of reference.Hôtel Mont Shefford (1970) Limitée.Les lots numéros un et deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre cent quatre-vingt-douze (492-1, 492-2) aux mêmes plan et livre de renvoi officiels.Hôtel Mont Shefford (1970) Limitée.Le lot numéro sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre cent quatre-vingt-onze (491-7) aux mêmes plan et livre de renvoi officiels.491-1,492-2 Lots numbers one and two of the official subdivision of original lot number four hundred ninety-two (492-1, 492-2) on said official plan and in said book of reference.491-7 Lot number seven of the official subdivision of original lot number four hundred ninety-one (491-7) on said official plan and in said book of reference.Hôtel Mont Shefford (1970) Limitée.Ces parties des lots cinq et six de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre cent quatre-vingt-onze (Pties 491-5 et 491-6) et du lot numéro cinq de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre cent quatre-vingt-dix (490-5) aux mêmes plan et livre de renvoi officiels décrites et bornées comme suit: commençant à l'intersection des lignes intérieures du trottoir en béton des rues Principale et St-Hubert; De là, vers le nord-ouest, longeant le trottoir de la rue Principale, une distance de cent soixante-dix pieds (170') jusqu'à un point sur la ligne intérieure du trottoir de cette rue; ce point étant appelé le point de départ; De ce point, longeant la limite est du trottoir de la rue St-Charles nord, une distance de quatre-vingt-dix-sept pieds (97') jusqu'à un point; De ce point, avec un angle de soixante-quatorze degrés (74°), une distance de cent vingt pieds (120') jusqu'à un point; De ce point, avec un angle de soixante-huit degrés (68°) une distance de quarante pieds (40'), jusqu'à la ligne nord-est du lot 491-5; De là, vers le sud-est, longeant la limite nord-est du lot 491-5, jusqu'au point d'intersection de la limite nord-est du lot 492-3 et de la limite sud-est du lot 491-5; De ce point, dans une direction sud, longeant la limite sud-est du lot 491-5, jusqu'au point d'intersection de la limite nord-est du lot 491-7 et de la limite sud-est du lot 491-5; De ce point, dans une direction nord-ouest, longeant la limite nord-est du lot 491-7, jusqu'au coin nord dudit lot 491-7; De là dans une direction sud-ouest, longeant la limite sud-est du lot 491-6, jusqu'au point d'intersection de la limite sud-est du lot 491-6 et de la limite nord-est du trottoir de la rue Principale; De là, longeant la limite nord-est du trottoir de la rue Principale, dans UDe direction nord-ouest, jusqu'au point \u2022 de départ.Bornées lesdites parties au sud-ouest par la rue Principale, à l'ouest par la rue St-Charles nord, au nord par parties des lots 490-6, 491-6 et 491-5, au nord-ouest, par une partie du lot 491-5, au nord-est par une partie du lot 491-4, au sud-est par le lot 492-3, au sud-ouest de nouveau, par le lot 491-7 et au sud-est de nouveau par le lot 491-7 ; Mesures anglaises.Sujettes certaines parties des lots 491-5 et 492-3 à un droit de passage en commun le tout tel que constitué aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Shefford, sous le numéro 133679.491-5 Ptie.491-6 Ptie, 490-5 Ptie Those parts of lots five and six of the official subdivision of original lot number four hundred ninety-one (Pts.491-5 and 491-6) and of lot number five of the official subdivision of original lot number four hundred ninety (490-5) on said official plan and in said book of reference, described and bounded as follows: starting at the point of intersection of the inside lines of the concrete sidewalks of Principale and St.Hubert Streets; Thence, towards the northwest, along the sidewalk of Principale Street over a distance of one hundred seventy feet (170') up to a point on the inside line of the sidewalk of that street ; this point being called the starting point; From said point, along the east limit of the sidewalk of St.Charles Street North, over a distance of ninety-seven feet (97') up to a point; From that point, at an angle of seventy-four degrees (74°), over a distance of one hundred twenty feet (120') up to a point; From that point, at an angle of sixty-eight (68°), over a distance of forty-feet (40'), up to the northeast limit of lot 491-5; Thence, towards the southeast, along the northeast limit of lot 491-5, up to the point where the northeast limit of lot 492-3 intersects the southeast limit of lot 491-5; From this point, in a southerly direction, along the southeast limit of lot 491-5, up to the point where the northeast limit of lot 491-7 intersects the southeast limit of lot 491-5; From this point, in a northwesterly direction, along the northeast limit of lot 491-7, up to the north corner of said lot 491-7; Thence, in a southwesterly direction, along the southeast limit of lot 491-6 up to the point where the southeast limit of lot 491-6 intersects the northeast limit of the sidewalk of Principal Street ; Thence, along the northeast limit of the sidewalk of Principale Street, in a northwesterly direction up to the starting point.The aforesaid parts being bounded on the southwest by Principale Street, on the west by St.Charles Street North, on the north by parts of lots 490-5, 491-6 and 491-5, on the northwest by a part of lot 491-5, on the northeast by a part of lot 491-4, on the southeast by lot 492-3, on the southwest again by lot 491-7 and on the southeast again by lot 491-7; English measure.Certain parts of lots 491-5 and 492-3 are subject to a common right-of-way as described in the terms of a deed registered at the Registry Office of the Division of Shefford, under number 133679. 1748 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol- 106, No.9 Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes attachées auxdits immeubles.Donné à Granby.en ce 14 février 1974.Le greffier de la ville, 56118-8-2-0 Don at Brosseau.Ville de Trois-Rivieres Avis public est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la susdite municipalité, que les propriétés ci-après décrites seront vendues a l'enchère publique, en la salle des délibérations du Conseil, à l'Hôtel de Ville de la Ville de Trois-Rivières, MERCREDI, le VINGTIÈME jour de MARS 1974, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes dues à la Ville de Trois-Rivières et à la Commission des Écoles Catholiques de Trois-Rivières, avec les intérêts et les frais, plus les frais subséquemment encourus, à moins que lesdites taxes, les intérêts et les frais ne soient payés avant la vente.Furthermore, said sale will include all active or passive, apparent or unapparent servitudes attaching to said immoveables.Given in Granby, February 14, 1974.Donat Brosseau, 56118-8-2 City Clerk.City of Trois-Rivières Public notice is hereby given by the undersigned, Clerk of the aforesaid Municipality, that the immoveables hereinafter described will be sold by public auction, in the Council Room, in the City Hall of the City of Trois-Rivières, on WEDNESDAY, the TWENTIETH day of MARCH, 1974, at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy the payment of taxes owed to the City of Trois-Rivières and to the Trois-Rivières Catholic School Board, plus interest and costs, together with the costs subsequently incurred, unless said taxes, interest and costs are paid prior to the sale.Taxes Taxes Propriétaire munie.scolaires Trottoir Lots Total Owner Munie.School Sidewalk taxes taxes Fortier.Real.1755-327 .Fortier, Real.1755-326 Fortier, Real.1125-65 .Vaillancourt, J.O.Joyal.P-1634.Vaillancourt.J.O.Joyal.P-1535.Vaillancourt.J.O.Joyal.P-1592.Les Immeubles Dessureault Ltée.P-685____ Cafor International Holdings Ltd.P-673-A.Godin.Gaston.P-828_____ Plouffe, Mme Vve J.Moïse.P-1019.Gouin Lumber Co.Ltd.26-P-793 Dupont, Jean-Jacques.26-A.Gélinas, Raymond.23-131.Gélinas, Raymond.1122-777.Laçasse, Claude.1130-34.Boucher, Pierre.1364-105.Lacroix, François.l-P-15 Lacroix.François.l-P-16., St-Pierre, Jean-Pierre.304.Langevin, Edouard.218-61 Gruninger, Carl.181-619.Lemire, Georges.1120-257 .Brien, Richard.173-134 .Duval.René.172-191.Paquin, Paul-Emile.185-42 378.40\tS 235\t.60\t\t$ 614.00 394.40\t254\t.60\t\t649.00 262.40\t243\t,20\t\t505.60 242.20\t127\t\t\t369.50 192.40\t121\t60\t\t314.00 194.00\t123\t.50\t\t317.50 3,288.20\t3,743\t.32\t\t7,031.52 763.63\t1,391\tMi\t\t2.165.49 1.223.29\t2,620\t.52\t\t3,843.81 17.60\t20\tno\t\t38.50 18.19\t470\t.80\t\t488.99 193.10\t148\t,20\t\t341.30 \t292\t.76\t\t292.75 \t159\t60\t\t159.60 502.00\t275\t.50\t\t777.60 269.20\t212\t80\t\t482.00 13.30\t19\t,00\tS 44.39\t76.69 18.62\t26\t1,0\t\t45.22 89.11\t127\t,30\t\t216.41 5.38\t\t\t\t5.38 \t\t\t52.64\t52.64 \t\t\t61.79\t61.79 \t\t\t61.39\t61.39 \t\t\t154.42\t154.42 \t\t\t34.20\t34.20 L'énumération abrégée des numéros cadastraux des immeubles a été autorisée par la Commission municipale de Québec en date du 14 janvier 1974, conformément aux dispositions de l'article 550 de la Loi des cités et villes.Donné à Trois-Rivières, ce 14e jour de février 1974.56120-8-2-o Le greffier de la Ville, Georges Beaumier.The Québec Municipal Commission, by a decision dated January 14, 1974, has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers, in conformity with the provisions of section 550 of the Cities and Towns Act.Given in Trois-Rivières, this 14th day of February, 1974.56120-8-2 Georges Beaumier, City Clerk. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n° 9 1749 Municipalité du comté de Huntingdon Avis public est donné par les présentes par la soussignée Mme M.A.Barrett, sécrétaire-trésorière du conseil du comté de Huntingdon, que les lots de terre, emplacements ou autres seront vendus à l'enchère publique, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MAI 1974, à DIX heures de l'avant-midi, à l'édifice du comté.Ville de Huntingdon, tant pour les taxes municipales, scolaires et autres restant dues à moins que ces diverses sommes et les frais encourus me soient payés avant le jour de la vente.Municipality of the County of Huntingdon Public notice is hereby given by the undersigned Mrs.M.A.Barrett, Secretary-Treasurer, of the aforesaid municipality, that the lands and buildings listed hereunder will be sold for the arrears of municipal, school, and other taxes due thereon together with costs, at a public sale of lands for arrears of taxes, at the County Building, Town of Huntingdon, on THURSDAY, the NINTH day of MAY 1974, at TEN o'clock in the forenoon, unless the said taxes and costs incurred are paid to me before the day of sale.Municipalité paroisse St-Anicet \u2014 Municipality Parish St.Anicct \t\t\tTaxes\tTaxes\t Noms\t\t\tmun.\tscol.\t \tLots nos.\tRg.\t\t\tTotal Names\t\t\tMunie, lazes\tSchool Taxes\t James Côté.516-10.Frank Delio.427.Roger Lavoie.598-6.Evelyn Tabor.590-59.Jean Théoret.513-23-32.Lise Bergeron.620 P.621.Robert Chapatis.590-88.Maurice Elias.319-321-32 la.Parmina Bercier Deniers.P.89.James Mrs.James.P.165-40-46.Philippe Lepage.P.559.i 36.85\t$ 154.34\tS 191.19 \t179.64\t179.64 \t161.07\t161.07 34.55\t148.26\t182.80 17.53\t\t17.53 449.56\t\t449.56 17.46\t\t17.46 148.96\t174.79\t323.75 31.92\t\t31.92 \t324.24\t324.24 \t154.44\t154.44 \tMunicipalité Canton de Dundee \u2014\tMunicipality Township of Dundee\t Vincenzo Lumbardo.\t.P.1.\t\t% 157.23 $ 157.23 \t\t\t \tMunicipalité Ville de Huntingdon \u2014\t- Municipality Town of Huntingdon\t Romeo Lefebvre.Albert Cadoret.Fournier Lumber.Roméo Robidoux Albert Cadoret.P.65.63.65-4 P.65.248.$ 100.44 22.00 121.00 88.00 70.50 88.11 315.03 39.64 350.49 170.94 110.11 436.03 39.64 438.49 \tMunicipalité Canton de Franklin -\t\u2014 Municipality Township of Franklin\t\t \t.27 a.c.d.\t.1\t1 15.23 !\tS 15.23 \t\t\t\t \tMunicipalité Canton de Havelock\t\u2014 Municipality Township of Havelock\t\t Jpsph Cunningham.P.73 d.2.Emile Letouze.32c.Pierre Morrissette.96.Mirella Chartrand.P.32a.Gaston Goucher.P.32c.Jean-Pierre Laberge.P.32c.Gaston Goucher.P.32c.Pierre Morrissette.96.Eric Hinchcliffe.P.32c.1.Mrs.Grace Lallemand.P.216.4.Howard McCracken.34a, 336, 35a.6, c.1.\t\tS 153.03\tt 153.03 3\t20\t14.38\t17.58 4\tSO\t26.05\t30.85 4\t80\t17.38\t22.18 6.\t40\t17.38\t23.78 4\t80\t17.38\t22.18 \t\t17.38\t17.38 \t\t34.75\t34.75 \t\t30.76\t30.76 \t\t669.60\t669.60 \t\t855.81\t855.81 1750 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.9 Names Worn* Lots nos.Rg.Taxes mun.M unie, taxes Taxes scol.School Taxes Mrs.Ethel C.Shaw.P.32.1.Mrs.Hazel Sorenson.P.43a.3.4.80 93.70 23.47 324.44 Municipalité Canton de Godmanchester \u2014 Municipality Township of Godmanchester Succ./Est.Doris Harrigan.400-401.5.Lee Smith.487-488-490.6.RenéLegault.P.296 .4.Mrs.Albert Deschambault.P.130.4.Alister Douglas.371-372 .5.4.35 49.60 1.75 80.70 464.46 446.52 Municipalité Canton de Hemmingford \u2014 Municipality Township of Hemmingford Total 28.27 418.14 80.70 468.81 49.60 1.75 446.52 Robert Laurin.106*.Bernard Hébert.183c.Innismere Farms Inc.101a-142d, e.143 a.c, «.Gavin Stairs.106i.2a, 46, 5d, 66, c, d.7a.76.3G.L.5G.L.t 577.93 416 139.83 437.83 ,477.52 6 S 416.76 139.83 437.83 ,055.45 Municipalité Paroisse Ste-Barbe \u2014 Municipality Parish Ste-Barbe Paul André Tremblay.P.36a.Léo Daoust.P.31c.Léo Daoust.P.31c.Léo Daoust.P.31c.Mich.Guillemette.P.48.Jacques Leboeuf.P.52 .Jean-Guy Robidoux.P.48.953.36 52.49 133.74 33.42 16.72 138.47 16.72 953.36 52.49 133.74 33.42 16.72 138.47 16.72 L'énumération abrégée des numéros a été autorisée par 1a Commission municipale du Québec, le 18 octobre 1967.Donné à Huntingdon, ce 15e jour du mois de février 1974.Le secrétaire-trésorier, 56135-8-2-0 Mme M.A.Barrett.The abreviated enumeration of the cadastral numbers has been authorized by the Québec Municipal Commission on October 18th 1967.Given at Huntingdon, this 15th dav of the month of February, 1974.Mrs.M.A.Barrett, 56135-8-2-q Secretary-Treasurer.Cité de Farnham Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier adjoint de la susdite municipalité, que: Les propriétés ci-apiès décrites seront vendues à l'enchère publique en la salle des délibérations du conseil de la Cité de Farnham, le VINGT-SEPTIÈME jour de MARS 1974, à DIX heures de l'avant-midi, pour payer les taxes municipales avec les intérêts et les frais, plus les frais subséquentes encourus, à moins que lesdites taxes, les intérêts et les frais ne soient payés avant la vente.La Commission municipale de Québec, par décision en date du 30 novembre 1973, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles sous l'autorité de la Loi des cités et villes, article 550 (S.R.Q.1964, chapitre 193).City of Farnham Puhlic notice is hereby given by the undersigned Assistant-Secretary-Treasurer of the aforesaid Municipality, that: The properties herein after described will be sold by public auction at the meeting room of the Council of the City of Farnham, on the TWENTY-SEVENTH day of MARCH 1974, at TEN o'clock in the morning, in payment of municipal taxes with interest and costs, plus the costs subsequently incurred, unless the said taxes, interest and costs are paid prior to the sale.The Québec Municipal Commission by a decision dated November 30, 1973, has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immoveables under the authority of article 550 of the Cities and Towns Act (R.S.Q.\"l964, chapter 193). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mart 1974, 106' année, n° 9 1751 Nom \u2014 Name Cadastre Montant dû: Taxes municipales et intérêts Amount of the municipal taxes and interest Chouinard, Jean-Louis.Pigeon, Marcel.Sansom-Babin, Shirley Mme-Mrs.Sansom Lome Philip et-and Sansom Robin Hope Bonnie.Bélanger, Mme-Mrs.Micheline.Smith, Laurier.McCorkill, Mme-Mrs.Mary Jane.Tétrault.John B.Inconnu \u2014 Unknown.Talon Development Inc., c/o Friedman, Blitzer & Co.Talon Development Inc., c/o Friedman, Blitzer & Co.P.213, Paroisse de-Parish of St-Romuald- 653-1, Ville de-Town of Farnham.P.292, Paroisse de-Parish of St-Romuald____ 283-127, Ville de-Town of Farnham.214-23 P., Paroisse de-Parish of St-Romuald.176, Ville de-Town of Farnham.174, Ville de-Town of Farnham.178.Ville de-Town of Farnham.213-29, Paroisse de-Parish of St-Romuald____ 213-45, Paroisse de-Parish of St-Romuald____ $ 397.07 1,010.09 532.41 371.01 744.39 33.50 19.70 41.84 13.04 19.63 L'acquéreur devra payer comptant ou par chèque certifié immédiatement après la vente.Donné à Farnham, ce 16e jour de janvier 1974.56177-9-2-0 Le secrétaire-trésorier adjoint, Jacques Desrosiers.The purchaser must pay in cash or by certified cheque immediately after the sale.Given at Farnham, this 16th day of January of 1974.56177-9-2-0 Jacques Desrosiers, Assistant-Secretary- Treasurer.Ville de Lorraine Avis public est par les présentes donné que le greffier de la Ville de Lorraine vendra à l'enchère publique le LUNDI, le VINGT-CINQUIÈME jour de MARS, 1974, à DIX heures de l'avant-midi au bureau du Conseil à l'Hôtel de Ville, 100 Grande Côte, Lorraine.Québec, de la manière prescrite par la loi, les immeubles suivants sur lesquels les taxes municipales n'ont cas été payées, à moins que ces taxes ne soient acquittées avec les frais encourus avant la vente, savoir: Town of Lorraine Public notice is hereby given that the Clerk of the Town of Lorraine will, on MONDAY, on the TWENTY-FIFTH day of MARCH, 1974 at TEN o'clock in the forenoon, at the office of the Council, Town Hall, 100 Grande Côte, Lorraine, Québec, sell at public auction, in the manner prescribed by law.the following immoveables on which the municipal taxes assessed have not been paid, unless those taxes together with the cost incurred be paid before the sale, to wit: Folio Nom \u2014 Name Numéro de cadastre Cadastral number 3-19 Mme-Mrs.G.Gamelin-Daoust.277-49-2, 277-50.3-23 M.R.Thompson.277-P.45.4-12 M.A.Leclerc.273-3, 273-4.274-1.Les immeubles susdits sont tous du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Thérèse de Blainville et situés dans le territoire de la Ville de Lorraine.La Commission municipale de Québec, en date du 15 février 1974, autorisait l'énumération abrégée des numéros cadastraux.Donné à Lorraine, ce 19e jour du mois de février 1974.56232-9-2-0 Le greffier, Mme N.C.Brazeau.The above immovables are all of the official cadastre of the parish of Ste.Thérèse de Blainville and situated in the Town of Lorraine.The Québec Municipal Commission on February 15th, 1974, authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers.Given at Lorraine, this 19th day of February 1974.56232-9-2-0 Mrs.N.C.Brazeau, Town Clerk. 1752 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March g, 1974.Vol- 106, No.9 Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 616-74 Québec.le 20 février 1974.Présent: le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'annexion d'un territoire non organisé à la municipalité scolaire Des Frontières.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'éducation: Que le territoire ci-dessous décrit, non organisé au point de vue scolaire, soit annexé, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire Des Frontières: 1° Le canton Bungay, dans le comté de Kamouraska.à l'exception de la partie sous la juridiction de la commission scolaire Jean Chapais; 2° Le canton Parke, dans le comté de Kamouraska.Que jusqu'à la fin de l'année scolaire 1974-1975.la division en quartiers de la municipalité scolaire Des Frontières soit maintenue à l'exception du quartier numéro 8 auquel est ajouté le canton Parke.dans le comté de Kamouraska.et du quartier numéro 9 auquel est ajouté le canton Bungay, dans le comté de Kamouraska.à l'exception de la partie sous la juridiction de la commission scolaire Jean Chapais.et ce, conformément aux articles 46, 49 et 64 de la Loi de l'instruction publique, Statuts refondus, 1964, chapitre 235.Le greffier du conseil exécutif.56268-o Julien Chouinard.Order in Council Executive Council Chamber Number 616-74 Québec.February 20, 1974.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting the annexation of a non organized territory to the Des Frontières School Municipality.It is ordered upon the recommendation of the Minister of Education: That the territory hereinafter described, non organized for school purposes, be annexed, for Catholics only, to the Des Frontières School Municipality: 1.The Township of Bungay, in the County of Kamouraska.except for that part which is under the jurisdiction of the Jean Chapais School Board; 2.The Township of Parke, in the County of Kamouraska.That, until the end of the 1974-1975 school year, the division into wards of the Des Frontières School Municipality be maintained, with the exception of ward number 8, to which is added the Township of Parke, in the County of Kamouraska, of ward number 9 to which is added the Township of Bungay, in the County of Kamouraska, and with the exception of that part which is under the jurisdiction of the Jean Chapais School Board.the foregoing pursuant to sections 46, 49 and 64 of the Education Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 235.Julien Chouinard, 56268 Clerk of the Executive Council.\\ Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 617-74 Québec, le 20 février 1974.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'annexion de certains territoires, pour catholiques seulement, à la municipalité scolaire de Outaouais-Hull.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'éducation: Que le territoire ci-dessous décrit soit détaché de la municipalité scolaire de la Haute Gatineau et annexé, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire de Outaouais-Hull: 1° Le canton de Low, dans le comté de Gatineau, 2\" Le canton d'Aylwin, dans le comté de Gatineau, moins les lots 43 à 46 inclusivement et 49 à 52 inclusivement des rangs IX, X et XI.Order in Council Executive Council Chamber Number 617-74 Québec, February 20, 1974.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting the annexation of certain territories, for Catholics only, to the School Municipality of Outaouais-Hull.It is ordered upon the recommendation of the Minister of Education: That the territory described hereinafter be detached from the School Municipality of Haute Gatineau and annexed, for Catholics only, to the School Municipality of Outaouais-Hull: 1.The Township of Low, in the County of Gatineau, 2.The Township of Aylwin.in the County of Gatineau, less lots 43 to 46 inclusive and 49 to 52 inclusive in Ranges IX, X and XI.Arrêtés en conseil Orders in Council GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1974, 106' année, n° 9 1753 Que jusqu'à la fin de l'année scolaire 1974-1975, la division en quartiers de la municipalité scolaire de Outaouais-Hull soit maintenue à l'exception du quartier 18 auquel est ajouté le canton de Low, dans le comté de Gatineau, et le canton d'Aylwin, dans le comté de Gatineau, moins les lots 43 à 46 inclusivement et 49 à 52 inclusivement des rangs IX, X et XI, et ce, conformément aux articles 46, 49, 51 et 64 de la Loi de l'instruction publique, Statuts refondus, 1964, chapitre 235.Le greffier du conseil exécutif, 56268-o Julien Chouinard.That until the end of the 1974-1975 school year, the division into wards of the School Municipality of Outaouais-Hull be maintained with the exception of Ward 18 to which shall be added the Township of Low in the County of Gatineau and the Township of Aylwin in the County of Gatineau, less lots 43 to 46 inclusive and 49 to 52 inclusive in Ranges IX, X and XI.in conformity with sections 46, 49, 51 and 64 of the Education Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 235.Julien Chouinard, 56268 Cleric of the Executive Council.Curatelle publique Succession Richard Laçasse Succession de Laçasse, Richard, en son vivant de Sherbrooke, décédé le 11 janvier 1974.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra à l'adresse ci-dessus, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent Montréal, P.Q.H2N 1N6 56178-o Succession Gaston Lavallée Succession de Gaston Lavallée, en son vivant de Sherbrooke, décédé le 21 août 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que., H2N 1N6.56244-0 Succession Fanny Raisman Succession de Mme Fanny Raisman, en son vivant de 4137, Esplanade, app.7, Montréal, décédée le 24 décembre 1971.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessus, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6.56266-o Public Curatorship Estate of Richard Laçasse Estate of the late Laçasse, Richard, in his lifetime of Sherbrooke, deceased January 11th, 1974.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mentioned address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal, P.Q.H2N 1N6 56178-o Estate of Gaston Lavallée Estate of the late Gaston Lavallée, in his lifetime of Sherbrooke deceased August 21, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal.Que., H2N 1N6.56244-0 Estate of Fanny Raisman Estate of the late Mrs.Fanny Raisman, in her lifetime of 4137, Esplanade, Apt.7, Montreal, deceased December 24, 1971.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address men-tionned below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal, Que., H2N 1N6.56266-o 1754 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March S, 1974.Vol.106, No.9 Ministère de l'Éducation Commission scolaire de la Haute Gatineau Commission scolaire de Outaouais-Hull Avis est par la présente donné qu'un certain territoire, comprenant le canton de Low ainsi que le canton d'Aylwin (moins les lots 43 à 46 inclusivement et 49 à 52 inclusivement des rangs IX, X et XI) a été détaché de la municipalité scolaire de la Haute Gatineau et annexé, pour catholiques seulement, à la municipalité scolaire de Outaouais-Hull.Et ce, en vertu de l'arrêté en conseil #617-74 du 20 février 1974, dont le texte suit: « Concernant l'annexion de certains territoires, pour catholiques seulement, à la municipalité scolaire de Outaouais-Hull.Que le territoire ci-dessous décrit soit détaché de la municipalité scolaire de la Haute Gatineau et annexé, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire de Outaouais-Hull: 1° Le canton de Low, dans le comté de Gatineau, 2° Le canton d'Aylwin, dans le comté de Gatineau, moins les lots 43 à 46 inclusivement et 49 à 52 inclusivement des rangs IX, X et XL Que jusqu'à la fin de l'année scolaire 1974-1975, la division en quartiers de la municipalité scolaire de Outaouais-Hull soit maintenue à l'exception du quartier 18 auquel est ajouté le canton de Low, dans le comté de Gatineau, et le canton d'Aylwin, dans le comté de Gatineau, moins les lots 43 à 46 inclusivement et 49 à 52 inclusivement des rangs IX, X et XI, et ce, conformément aux articles 46, 49, 51 et 64 de la Loi de l'instruction publique.Statuts refondus, 1964, chapitre 235.» Ce changement prendra effet le premier juin 1974 pour les fins d'élection, et le premier juillet pour toutes autres fins.Le 25 février 1974.Le ministre de l'éducation, 56268-0 François Cloutier.Municipalité scolaire des frontières Avis est par la présente donné qu'un certain territoire non organisé au point de vue scolaire, comprenant le canton Bungay (sauf la partie appartenant à la municipalité scolaire Jean Chapais) et le canton Parke, a été annexé pour catholiques seulement, à la municipalité scolaire Des Frontières.Et ce, en vertu de l'arrêté en conseil #616-74 du 20 février 1974, dont le texte suit: « Concernant l'annexion d'un territoire non organisé à la municipalité scolaire Des Frontières.Que le territoire ci-dessous décrit, non organisé au point de vue scolaire, soit annexé, pour catholiques seulement, à la Municipalité scolaire des Frontières: Department of Education The Haute Gatineau School Board The Ontaouais-Hull School Board Notice is hereby given that a certain territory comprising the township of Low and the township of Ayl-win (less lots 43 to 46 inclusive and 49 to 52 inclusive in Ranges IX.X and XI) has been detached from the School Municipality of Haute Gatineau and annexed, that is, for Catholics only, to the School Municipality of Outaouais-Hull.The foregoing in conformity with Order in Council No.617-74 dated February 20, 1974, which reads as follows: \"Respecting the annexation of certain territories, for Catholics only, to the School Municipality of Outaouais-Hull.That, the territory described hereinafter be detached from the School Municipality of Haute Gatineau and annexed, for Catholics only, to the School Municipality of Outaouais-Hull : 1.The Township of Low, in the County of Gatineau, 2.The Township of Aylwin, in the County of Gatineau, less lots 43 to 46 inclusive and 49 to 52 inclusive in Ranges IX, X and XI.That until the end of the 1974-1975 school year, the division into wards of the School Municipality of Outaouais-Hull be maintained, with the exception of Ward 18, to which shall be added the Township of Low in the County of Gatineau and the Township of Aylwin in the County of Gatineau, less lots 43 to 46 inclusive and 49 to 52 inclusive in Ranges IX, X and XI, in conformity with sections 46, 49, 51 and 64 of the Education Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 235.\" This change shall take effect on June first, 1974 for purposes of elections and on July first for all other purposes.February 25, 1974.François Cloutier, 56268 Minister of Education.The Des Frontières School Municipality Notice is hereby given that a certain territory non organized for school purposes, comprising the Township of Bungay (except for the part belonging to the Jean Chapais School Municipality) and the Township of Parke, has been annexed, for Catholics only, to the Des Frontières School Municipality.The foregoing, pursuant to Order in Council No.616-74, dated February 20, 1974, which reads as follows: \"Respecting the annexation of a non organized territory to the Des Frontières School Municipality.That the territory hereinafter described, non organized for school purposes, be annexed, for Catholic:, only, to the Des Frontières School Municipality: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n° 9 1755 1° Le canton Bungay, dans le comté de Kamouraska, à l'exception de la partie sous la juridiction de La Commission scolaire Jean Chapais; 2° Le canton Parke, dans le comté de Kamouraska.Que jusqu'à la fin de l'année scolaire 1974-1975, la division en quartiers de la municipalité scolaire Des Frontières soit maintenue à l'exception du quartier numéro 8 auquel est ajouté le canton Parke, dans le comté de Kamouraska, et du quartier numéro 9 auquel est ajouté le canton Bungay, dans le comté de Kamouraska, à l'exception de la partie sous la juridiction de La Commission scolaire Jean Chapais.et ce, conformément aux articles 46, 49 et 64 de la Loi de l'instruction publique, Statuts refondus, 1964, chapitre 235.\" Ce changement prendra effet 15 jours suivant la date du présent arrêté en conseil.Le 25 février 1974.Le minisire de l'éducation, 56268-0 François Cloutier.Ministère du Revenu L'avis d'intention d'annulation suivant fut envoyé à l'oeuvre, la corporation ou la fiducie indiquée ci-dessous et, en vertu de l'article 789 (1 ) de la Loi sur les impôts, l'annulation entre en vigueur à la date de publication dans cette édition de la Gazette officielle du Québec.Nous désirons vous informer de l'intention du ministre du Revenu d'annuler l'enregistrement de votre organisme au titre d'oeuvre de charité ou d'association d'athlétisme amateur prescrite.Cette radiation est en conformité avec les prescriptions des articles 787 et 788 de la Loi sur les impôts et du règlement 532.3 adopté le 30 décembre 1972, sous l'empire de ladite loi.Nom / .Name Adresse / Address Ahuntsic-Galbraith United Church 3480 Decarie Blvd.Montreal 28, Que.Congregation (ETZ Chaim) of Montreal 2477 Bedford Road Montreal, Que.Protestant Board of School Trustees of Verdun 1201 Argyle Avenue Verdun 204, Que.1.The Township of Bungay, in the County of Kamouraska, except for that part which is under the jurisdiction of the Jean Chapais School Board; 2.The Township of Parke, in the County of Kamouraska.That until the end of the 1974-1975 school year, the division in to wards of the Des Frontières School Municipality be maintained, with the exception of Ward number 8 to which is added the Township of Parke, in the County of Kamouraska, of ward number .9, to which is added the Township of Bungay, in the County of Kamouraska, and of that part which is under the jurisdiction of the Jean Chapais School Board.the foregoing, pursuant to sections 46, 49 and 64 of the Education Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 235.\" This change shall come into force 15 days following the date of publication of this Order in Council, February 25, 1974.François Cloutier, 56268 Minister of Education.Department of Revenue The following notice of proposed revocation was sent to the charitable organization, corporation or trust listed below and by virtue of paragraph 789 (1) of the Taxation Act, the revocation is effective on the date of publication in this issue of the Québec Official Gazette.Please be informed of the Minister's intention to revoke the registration of your charitable organization or amateur athletic association previously recognized or authorized by regulation.This revocation is in conformity with sections 787 and 788 of the Taxation Act and regulation 532.3 which was sanctioned on December 30, 1972, under the authority of the said Act.Numéro Genre Date d'envoi Number Type Mailing date 0105379-44-08 Organisme 18-01-74 0242735-42-08 Organisme 18-01-74 0347559-21-08 Organisme 18-01-74 1756 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.9 Nom / Name Adresse / Address Numéro Genre Date d'envoi Number Type Mailing date The Salvation Army Park Extension Corps 4244 Powell Avenue Montreal, Que.St.Barnabas' Church Compton Québec.St.John's Church R.R.1 Lac Mégantic, Que.St-Lambert Baptist Church 236 Desaulniers Blvd.St.Lambert, Que.Young Piople's Congregation of Spiritual and Secular Knowledge (Congragation ZEI) 12 Bagg Avenue Montreal, Que.Armé du Salut Bureau régional 4488, rue Adam Montréal 403.Que.Auxiliaires Féminines Internationales Catholiques 3125, rue Barclay, app.2 Montréal.Que.Cénacle de Paix 365, rue Cowie Granby (Shefford) Que.Chapelle Baptiste Evangéiique de Chomedey 1908, rue Maisonneuve Chomedey, Que.Chapelle de la Foi Internationale 8e rue ouest Amos (Abitibi est) Que.Drogue Secours Boule de Neige Inc.Gouvernement du Québec 969, route de l'Eglise Québec 10, Que.Église du Christ 655, 5e Avenue I.achine, Que.0170746-40-08 Organisme 18-01-74 0084020-304)7 Organisme 184)1-74 0084210-304)7 Organisme 184)1-74 0155051-314)8 Organisme 18-01-74 0136218-424)8 Organisme 184)1-74 0383851404)8 Organisme 184)1-74 0291815-094)8 Organisme 18-01-74 0337352-394)7 Organisme 184)1-74 0228205-314)8 Organisme 184)1-74 0255927-394)9 Organisme 184)1-74 0393553-574)6 Organisme 184)1-74 0309526-394)8 Organisme 184)1-74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n° 9 1757 Nom / Name Adresse / Address Numéro Genre Date d'envoi Number Type Mailing dale Église Évangélique Baptiste '?3Î, rue St-Jean Baptiste Thetford Mines, Que.La Fabrique de la paroisse d'East Broughton East Broughton Beauce, Que.Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-Fatima 501, boul.Centenaire Jonquière La Fabrique de la paroisse de St-Benoît 1106, rue Grenade Chambly, Que.La Fabrique de la paroisse de St-Claude St-CIaude, Que.La Fabrique de la paroisse de St-Côme Linière (Beauce), Que.Fabrique de la Paroisse de St-Hugues St-Hugues, Que.La Fabrique de la Paroisse de St-Jean-Eudes 2000, boul.Marie Laflèche, Que.La Fabrique de la paroisse St-Joseph-de-Cap-d'Espoir Cap-d'Espoir (Gaspé-sud), Que.La Fabrique de la paroisse de St-Joseph-de-la-Rive St-Joseph-de-la-Rive, Que.La Fabrique de la paroisse de St-Patrice 765 Buck Street Sherbrooke, Que.La Fabrique de la paroisse de St-Robert-Bellarmin R.R.2 St-Robert-Bellarmin Beauce, Que.La Fabrique de la paroisse de St-Wilfrid Kingscroft, Que.La Fabrique de la paroisse Ste-Brigite-de-Maria CP.9 Ste-Brigite-de-Maria, Que.Fabrique de St-Charles-Borromée Drummond 88, rue Pie-XII Drummondville, Que.0302745-31-06 Organisme 18-01-74 0070326-38-06 Organisme 18-01-74 0329565-38-06 Organisme 18-01-74 0066464-38-08 Organisme 18-01-74 0070771-38-07 Organisme 18-01-74 0070060-38-06 Organisme 18-01-74 0006155-38-07 Organisme 18-01-74 0066720-38-08 Organisme 18-01-74 0077537-38-06 Organisme 18-01-74 0067959-38-O6 Organisme 18-01-74 0071563-38-07 Organisme 18-01-74 0068718-38-06 Organisme 18-01-74 0071837-38-07 Organisme 18-01-74 0077388-38-06 Organisme 18-01-74 0016949-38-07 Organisme 18-01-74 175S QUÉBEC OFFICIAI, GAZETTE, March S, 1974, Vol.106, No.9 Nom / Name Adresse / Address Numéro Number Fabrique St-Maurice C.P.250, Labrieville Saguenay, Que.Fabrique St-René-Goupil St-René de Matane Que.Mission Néerlandaise (Hollandais et Flammands) Archidiocèse de Montréal 2830, boul.Gouin est Montréal 360.Que.Paroisse St-André Belleterre Que.Paroisse St-Ignace Cloutier, Que.Séminaire St-François (Capucins) 4900.rue St-Félix Cap-Rouge.Que.G0A 1K0 Société St-Vincent de Paul Conférence Féminine St-Jérôme de l'Auvergne 6020.3e Avenue Est Charlesbourg, Que.Société St-Vincent de Paul Conférence Féminine St-Thomas d'Aquin 898, rue Rochette Québec 10, Que.La Société St-Vincent de Paul Conférence Ste-Odile 11781, boulevard St-Germain Montréal Que.La Société de St-Vincent de Paul Conseil Particulier Féminin Immaculée-Conception 433, nie Queen Rawdon (Montcalm), Que.Soeurs Missionnaires de l'Immaculéc-Conception 7535, me St-Dominique Montréal 327.Que.Fabrique de St-Lucien (Drummond) St-Lucicn Drummond.Que.Date d'envoi Mailing date 0026633-38-06 Organisme 18-01-74 0065458-38-06 Organisme 18-01-74 00165464-38-08 Organisme 18-01-74 0003368-38-09 Organisme 18-01-74 0003392-38-09 Organisme 18-01-74 0180141-20-06 Organisme 18-01-74 0255760-09-06 Organisme 18-01-74 0255679-09-06 Organisme 18-01-74 0141820-09-08 Organisme 18-01-74 0284281-09-08 Organisme 18-01-74 0044222-20-06 Organisme 18-01-74 0017285-38-07 Organisme 18-01-74 /.e chef du service de l'accréditation.Direction des programmes et méthodes, 56199-o Robert Motard.56199-o Robert Motard.Chief - Accreditation Service, Programs and Methods Bureau Genre Type GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1974, 106' année, n° 9 1759 Proclamations Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.) ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que, conformément à l'article 1 de la Lo1 du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964.chapitre 320), il a été préparé, sous la direction du ministre des terres et forêts, un plan d'une partie du canton de Hébert, comprenant le bloc D, située dans la division d'enregistrement de Chicoutimi, avec un livre de renvoi relatif à ce plan; Attendu que le plan de cette partie dudit canton qui est signé par le ministre des terres et forêts est dans les archives de son bureau; Attendu Qu'une copie de ce plan correct, accompagné d'une copie de ce livre de renvoi, a été déposée par le ministre des terres et forêts au bureau de la division d'enregistrement de Chicoutimi, à Chicoutimi; Attendu que, maintenant, il y a lieu d'annoncer,, selon les prescriptions de l'article 2169 du Code civil par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil le dépôt des plan et livre de renvoi originaires dans la division d'enregistrement de Chicoutimi, et, en même temps, le jour auquel les dispositions de l'article 2168 y deviendront en vigueur, le tout relativement à ladite partie du canton de Hébert.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 335-74, du 30 janvier 1974, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), ainsi qu'aux articles 2166 à 2176c inclusivement du Code civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II de ce Code dont le titre est « Du plan et du livre de renvoi officiels et dispositions qui s'y rattachent », qu'il y a lieu: a) d'annoncer le dépôt, par le ministre des terres et forêts, au bureau de la division d'enregistrement de Chicoutimi, à Chicoutimi, des plan et livre de renvoi originaires, d'une partie du canton de Hébert, comprenant le bloc D, située dans la division d'enregistrement de Chicoutimi ; 6) de fixer à la date de la publication de la présente proclamation le jour auquel les dispositions de l'article 2168 deviendront en vigueur, dans cette division d'en- Proclamations Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom.Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas, pursuant to section 1 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, chapter 320) the Minister of Lands and Forests has caused to be prepared, under his superintendence, a correct plan of a part of the Township of Hébert, comprising Block D, located in the Chicoutimi Registration Division, with a book of reference relating to this correct plan; Whereas the correct plan of this part of the said Township signed by the Minister of Lands and Forests, is in the Archives of his office; Whereas a copy of this correct plan, together with a copy of this book of reference has been deposited in the Chicoutimi Registration Division Office, in Chicoutimi by the Minister of Lands and Forests; Whereas it is now expedient, pursuant to the provisions of article 2169 of the Civil Code, to announce, by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, the deposit of the original plan and book of reference in the Chicoutimi Registration Division, and.at the same time, the day on which the provisions of article 2168 will become effective, the whole in relation to the said part of the Township of Hébert.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 335-74, dated January 30.1974.We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and pursuant to sections 1 and 2 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964.Chapter 320), and articles 2166 to 2176c inclusive of the Civil Code, that is to say, those constituting Section II of this Code, the title of which is \"of the Official Plans and Books of Reference and of Matters Connected Therewith\", that it is expedient: (a) to announce the deposit in the Chicoutimi Registration Division Office, in Chicoutimi, of the original plan and book of reference of a part of the Township of Hébert, comprising Block D.located in the Chicoutimi Registration Division, by the Minister of Lands and Forests; (6) to fix the date of the publication of this proclamation as the day on which the provisions of article 2168 will become effective in this Registration Division, in 1760 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March S, 1971,, Vol.106, No.9 rcgistrement, relativement à ladite partie du canton de Hébert; c) de rappeler que, dans les deux ans qui suivent cette date, l'enregistrement de tout droit réel, sur un lot de terre désigné sur ces plan et livre de renvoi, doit être renouvelé par l'enregistrement par dépôt, d un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite dans l'article 2168 et en observant les autres formalités prescrites dans l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques; d) d'informer qui de droit que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe.c.p.c.r.lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce trentième jour de janvier en l'année mil neuf cent soixante-quatorze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Libro: 501 Jean Alarie.Folio: 198 56162-0 relation to the said part of the Township of Hébert; (c) to direct attention to the fact that, within two years from this date, the registration of any real right upon a lot of land described in this plan and book of reference must be renewed by means of the registration, by deposit, of a notice describing the immoveable affected, in the manner prescribed in article 2168 and in conformity with the other formalities prescribed in article 2131 for the ordinary renewal of the registration of hypothecs; (d) to notify whom it may concern that if such renewal be not effected, the real rights preserved by the first registration will have no effect against other creditors or subsequent purchasers whose claims have been registered in due form.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly; In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c.q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Quéliec.in Our Province of Québec, this thirtieth day of January, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-four and in the twenty-second year of Our Reign.By command, Jean Alarie, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 198 56162 Canada, Province de Hl'GUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grace de Dieu, Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que.conformément à l'article 1 de la Loi du cadastre (Statuts refondas du Québec, 1964.chapitre 320).il a été préparé, sous la direction du ministre des terres et forêts, un plan d'une partie du canton d'Isle-Dieu, comprenant le bloc 64, située dans la division d'enregistrement d'Abitibi avec un livre de renvoi relatif à ce plan; Canada.Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.) ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas, pursuant to section 1 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, chapter 320), the Minister of Lands and Forests has caused to be prepared, under his superintendence, a correct plan of a part of the Township of Isle-Dicu, comprising 64 located in the Abitibi Registration Division, with a book of reference relating to this correct plan ; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n8 9 1761 Attendu que le plan de cette partie dudit canton qui est signé par le ministre des terres et forêts est dans les archives de son bureau; Attendu Qu'une copie de ce plan correct, accompagné d'une copie de ce livre de renvoi, a été déposée par le ministre des terres et forêts au bureau de la division d'enregistrement d'Abitibi, à Amos; Attendu que, maintenant, il y a lieu d'annoncer, selon les prescriptions de l'article 2169 du Code civil, par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, le dépôt des plan et livre de renvoi originaires dans la division d'enregistrement d'Abitibi, et, en même temps, le jour auquel les dispositions de l'article 2168 y deviendront en vigueur, le tout relativement à ladite partie du canton d'Isle-Dieu; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 445-74, du 6 février 1974, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), ainsi qu'aux articles 2166 à 2176c inclusivement du Code civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II de ce Code dont le titre est « Du plan et du livre de renvoi officiels et dispositions qui s'y rattachent », qu'il y a lieu: a) d'annoncer le dépôt, par le ministre des terres et forêts, au bureau de la division d'enregistrement d'Abitibi, à Amos, des plan et livre de renvoi originaires d'une partie du canton d'Isle-Dieu, comprenant le bloc 64, située dans la division d'enregistrement d'Abitibi; 6) de fixer à la date de la publication de la présente proclamation le jour auquel les dispositions de l'article 2168 deviendront en vigueur, dans cette division d'enregistrement, relativement à ladite partie du canton d'Isle-Dieu; c) de rappeler que, dans les deux ans qui suivent cette date, l'enregistrement de tout droit réel, sur un lot de terre désigné sur ces plan et livre de renvoi, doit être renouvelé par l'enregistrement par dépôt, d'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite dans l'article 2168 et en observant les autres formalités prescrites dans l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques; d) d'informer qui de droit que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Whereas the correct plan of this part of the said Township signed by the Minister of Lands and Forests, is in the Archives of his office; Whereas a copy of this correct plan, together with a copy of this book of reference has been deposited in the Abitibi Registration Division Office, in Amos by the Minister of Lands and Forests; Whereas it is now expedient, pursuant to the provisions of article 2169 of the Civil Code, to announce, by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, the deposit of the original plan and book of reference in the Abitibi Registration Division, and.at the same time, the day on which the provisions of article 2168 will become effective, the whole in relation to the said part of the Township of Isle-Dieu; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 445-74, dated February 6, 1974, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and pursuant to sections 1 and 2 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320).and articles 2166 to 2176c inclusive of the Civil Code, that is to say, those constituting Section II of this Code, the title of which is \"of the Official Plans and Books of Reference and of Matters Connected Therewith\", that it is expedient: (a) to announce the deposit in the Abitibi Registration Division Office, in Amos, of the original plan and book of reference of a part of the Township of Isle-Dieu, comprising block 64, located in the Abitibi Registration Division, by the Minister of Lands and Forests; (6) to fix the date of the publication of this proclamation as the day on which the provisions of article 2168 will become effective in this Registration Division, in relation to the said part of the Township of Isle-Dieu; (c) to direct attention to the fact that, within two years from this date, the registration of any real right upon a lot of land described in this plan and book of reference must be renewed by means of the registration, by deposit, of a notice describing the immoveable affected, in the manner prescribed in article 2168 and in conformity with the other formalities prescribed in article 2131 for the ordinary renewal of the registration of hypothecs; (d) to notify whom it may concern that if such renewal be not effected, the real rights preserved by the first registration will have no effect against other creditors or subsequent purchasers whose claims have been registered in due form.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly; In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; 1762 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.9 Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapoistk.c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hotel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce sixième jour de février en l'année mil neuf cent soixante-quatorze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-troisième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Libro: 501 Jean Alarie.Folio: 200 56162-o Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this sixth day of February in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-four and in the twenty-third year of Our Reign.By command, Libro: 501 Folio: 200 Jean Alarie, ¦issistant Deputy Attorney General.56162 Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.) ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth.Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que.conformément à l'article 1 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), il a été préparé, sous la direction du ministre des terres et forêts, un plan d'une partie du canton de Falardeau, comprenant les lots 1 à 66.rang F et des Iles 22 à 26, située dans la division d'enregistrement de Chicoutimi, avec un livre de renvoi relatif à ce plan; Attendu que le plan de cette partie dudit canton qui est signé par le ministre des terres et forêts est dans les archives de son bureau; Attendu Qu'une copie de ce plan correct, accompagné d'une copie de ce livre de renvoi, a été déposée par le ministre des terres et forêts au bureau de la division d'enregistrement de Chicoutimi, à Chicoutimi; Attendu que.maintenant, il y a lieu d'annoncer, selon les prescriptions de l'article 2169 du Code civil, par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, le dépôt des plan et livre de renvoi originaires dans la division d'enregistrement de Chicoutimi, et, en même temps, le jour auquel les dispositions de l'article 2168 y deviendront en vigueur, le tout relativement à ladite partie du canton de Falardeau.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 243-74.du 24 janvier 1974, Nous avons décrété et ordonné et.par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec.1964, chapitre 320), ainsi qu'aux articles 2166 à 2176c inclusivement du Coile civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II «le ce Code dont le titre est « Du plan et du livre de Canada.Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom.Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas, pursuant to section 1 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, chapter 320), the Minister of Lands and Forests has caused to be prepared, under his superintendence, a correct plan of a part of the Township of Falardeau, comprising lots 1 to 66, Range F and Islands 22 to 26 located in the Chicoutimi Registration Division, with a book of reference relating to this correct plan; Whereas the correct plan of this part of the said Township signed by the Minister of Lands and Forests, is in the Archives of his office; Whereas a copy of this correct plan, together with a copy of this book of reference has been deposited in the Chicoutimi Registration Division Office, in Chicoutimi by the Minister of Lands and Forests; Whereas it is now expedient, pursuant to the provisions of article 2169 of the Civil Code, to announce, by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, the deposit of the original plan and book of reference in the Chicoutimi Registration Division, and.at the same time, the day on which the provisions of article 2168 will become effective, the whole in relation to the snid part of the Township of Falardeau.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 243-74, dated January 24, 1974, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and pursuant to sections 1 and 2 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320), and articles 2166 to 2176c inclusive of the Civil Code, that is to say.those constituting Section II of this Code, the title of which is \"of the Official Plans and Books of GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 197i, 106' année, n° 9 1763 renvoi officiels et dispositions qui s'y rattachent », qu'il y a lieu: a) d'annoncer le dépôt, par le ministre des terres et forêts, au bureau de la division d'enregistrement de Chicoutimi, à Chicoutimi, des plan et livre de renvoi originaires d'une partie du canton de Falardeau, comprenant les lots 1 à 66, rang F et des îles 22 à 26, située dans la division d'enregistrement de Chicoutimi; 6) de fixer à la date de la publication de la présente proclamation le jour auquel les dispositions de l'article 2168 deviendront en vigueur, dans cette division d'enregistrement, relativement à ladite partie du canton de Falardeau; c) de rappeler que, dans les deux ans qui suivent cette date, l'enregistrement de tout droit réel, sur un lot de terre désigné sur ces plan et livre de renvoi, doit être renouvelé par l'enregistrement par dépôt, d'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite dans l'article 2168 et en observant les autres formalités prescrites dans l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques; d) d'informer qui de droit que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-quatrième jour de janvier en l'année mil neuf cent soixante-quatorze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Libro: 501 Jean Alarie.Folio: 197 56162-0 Canada.Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Reference and of Matters Connected Therewith\", that it is expedient: (a) to announce the deposit in the Chicoutimi Registration Division Office, in Chicoutimi, of the original plan and book of reference of a part of the Township of Falardeau, comprising lots 1 to 66, Range F and Islands 22 to 26 located in the Chicoutimi Registration Division, by the Minister of Lands and Forests; (6) to fix the date of the publication of this proclamation as the day on which the provisions of article 2168 will become effective in this Registration Division, in relation to the said part of the Township of Falardeau; (c) to direct attention to the fact that, within two years from this date, the registration of any real right upon a lot of land described in this plan and book of reference must be renewed by means of the registration, by deposit, of a notice describing the immoveable affected, in the manner prescribed in article 2168 and in conformity with the other formalities prescribed in article 2131 for the ordinary renewal of the registration of hypothecs; (d) to notify whom it may concern that if such renewal be not effected, the real rights preserved by the first registration will have no effect against other creditors or subsequent purchasers whose claims have been registered in due form.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly; In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c., q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twenty-fourth day of January, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-four and in the twenty-second year of Our Reign.By command, Jean Alarie, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 197 56162 Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting. 1764 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 2, 1974, Vol- 106, A'o.9 Proclamation Attendu que, conformément à l'article 1 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964.chapitre 320), il a été préparé, sous la direction du ministre des terres et forets, un plan d'une partie du canton de Câlinée, comprenant le bloc 39.située dans la division d'enregistrement d'Abitibi, avec un livre de renvoi relatif à ce plan; Attendu que le plan de cette partie dudit canton qui est signé par le ministre des terres et forêts est dans les archives de son bureau: Attendu qu'une copie de ce plan correct, accompagné d'une copie de ce livre de renvoi, a été déposée par le ministre des terres et forêts au bureau de la division d'enregistrement d'Abitibi, à Amos; Attendu que, maintenant, il y a lieu d'annoncer, selon les prescriptions de l'article 2169 du Code civil, par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, le dépôt des plan et livre de renvoi originaires dans la division d'enregistrement d'Abitibi, et, en même temps, le jour auquel les dispositions de l'article 2168 y deviendront en vigueur, le tout relativement à ladite partie du canton d'Atibiti.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 444-74, du 6 février 1974, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320).ainsi qu'aux articles 2166 à 2176c inclusivement du Code civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II de ce Code dont le titre est « Du plan et du livre de renvoi officiels et dispositions qui s'y rattachent », qu'il y a lieu: a) d'annoncer le dépôt, par le ministre des terres et forêts, au bureau de la division d'enregistrement d'Abitibi, à Amos, des plan et livre de renvoi originaires d'une partie du canton de Ualinée, comprenant le bloc 39, située dans la division d'enregistrement d'Abitibi; 6) de fixer à la date de la publication de la présente proclamation le jour auquel les dispositions de l'article 2168 deviendront en vigueur, dans cette division d'enregistrement, relativement à ladite partie du canton de Galinée; c) de rappeler que, dans les deux ans qui suivent cette date, l'enregistrement de tout droit réel, sur un lot de terre désigné sur ces plan et livre de renvoi, doit être renouvelé par l'enregistrement par dépôt, d'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite dans l'articl 2168 et en observant les autres formalités prescrites dans l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques; d) d'informer qui de droit que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont Proclamation Whereas, pursuant to section 1 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320), the Minister of Lands and Forests has caused to be prepared, under his superintendence, a correct plan of a part of the Township of Galinée, comprising block 39, located in the Abitibi registration division, with a book of reference relating to this correct plan ; Whereas the correct plan of this part of the said Township signed by the Minister of tands and Forests, is in the Archives of his office; Whereas a copy of this correct plan, together with a copy of this book of reference has been deposited in the Abitibi registration division office, in Amos by the Minister of Lands and Forests; Whereas it is now expedient, pursuant to the provisions of article 2169 of the Civil Code, to announce, by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, the deposit of the original plan and book of reference in the Abitibi registration division, and.at the same time, the day on which the provisions of article 2168 will become effective, the whole in relation to the said part of the Township of Abitibi.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 444-74.dated February 6.1974, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and pursuant to sections 1 and 2 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec.1964.Chapter 320), and articles 2166 to 2176c inclusive of the Civil Code, that is to say, those constituting Section II of this Code, the title of which is \"of the Official Plans and Books of Reference and at Matters Connected Therewith\", that it is expedient: (a) to announce the deposit in the Abitibi Registration Division Office, in Amos, of the original plan and book of reference of a part of the Township of Galinée, comprising block 39 located in the Abitibi registration division, by the Minister of Lands and Forests; (6) to fix the date of the publication of this proclamation as the day on which the provisions of article 2168 will become effective in this registration division, in relation to the said part of the Township of Galinée; (c) to direct attention to the fact that, within two years from this date, the registration of any real right upon a lot of land described in this plan and book of reference must be renewed by means of the registration, by deposit, of a notice describing the immoveable affected, in the manner prescribed in article 2168 and in Conformity with the other formalities prescribed in article 2131 for the ordinary renewal of the registration of hypothecs; (a) to notify whom it may concern that if such renewal be not effected, the real rights preserved by the first registration will have no effect against other creditors or subsequent purchasers whose claims have been registered in due form.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mars 1974, 106' année, n° 9 1765 requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icellcs apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce sixième jour de février en l'année mil neuf cent soixante-quatorze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-troisième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Libro: 501 René Langevin.Folio: 199 56162-o to take notice and to govern themselves accordingly; In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c., Q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this sixth day of February in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-four and in the twenty-third year of Our Reign.By command.René Langevin, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 199 56162 Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la forêt est une des plus importantes richesses du Québec; Attendu Qu'il importe, dans l'intérêt de l'Etat, d'assurer par tous les moyens possibles, la conservation, l'aménagement rationel et la restauration de cette richesse; Attendu que, pour réaliser cela, il est essentiel que la population ait le respect de l'arbre et soit pleinement consciente de ses responsabilités envers la forêt; Attendu que la proclamation d'une « Semaine de l'Arbre et de la Forêt » a pour but de rappeler les bienfaits que procurent l'arbre et la forêt; Vu l'article 165 de la Loi des terres et forêts (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 92).A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 443-74, du 6 février 1974, Nous avens décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts: Qu'une semaine soit nommément consacrée au culte de l'arbre et de la forêt et que la période du 5 au 11 mai 1974 inclusivement soit proclamée officiellement la « Semaine de l'Arbre et de la Forêt » au Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont Canada Province of HUGUES LAPOINTE Québec [L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealtn, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern.Greeting.Proclamation Whereas the forest is one of the most important natural resources of the Province of Québec; Whereas it is expedient, in the interest of the State, to ensure by every possible means, the conservation, the rational management and the restoration of this resource; Whereas, in order to achevé such an end, it is essential that the population have a respect for trees and that it be fully aware of its responsibilities regarding the forests; Whereas the purpose of proclaiming an « Arbor and Forest Week\" is to draw attention to the benefits diiived from trees and forests; Considering section 165 of the Lands and Forests Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 92).Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 443-74, dated February 6, 1974, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests: That a week be devoted particularly to the respect of trees and forests, and that the period extending from May 5 to May 11,1974 inclusive be officially proclaimed \"Arbor and Forest Week\" in the Province of Québec.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are herebv 1766 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 2, 1974.Vol.106.So.9 requis de prendre connaissance el de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce sixième jour de février en l'année mil neuf cent soixante-quatorze et de Notre Règne la vingt-troisième année.Par ordre.Libro: 501 Folio: 201 Le sous-procureur général adjoint, René Langevin.56162-o required to take notice and to govern themselves accordingly; In testimony whereof, We have caused Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed: Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Building.', in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this sixth day of February in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-four and in the twenty-third year of Cur Reign.By command, René Langevin, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 201 56162 Régie de l'électricité et du gaz Electricity and Gas Board GAZ METROPOl ITAIN, INC.et GAZ DU QUEBEC, INC.Demande de droit exclusif de distribuer du gaz dans les cités de Sherbrooke et Trois-Rivières, P.Q., etc.Avis est donné par les présentes que la Régie de l'électricité et du gaz a reçu de GAZ METROPOLITAIN INC.une demande de droit exclusif de distribuer du gaz dans les cités de Trois-Rivières et de Sherbrooke, P.Q.aux lieu et place de GAZ DU QUEBEC, INC.qui demande l'autorisation de vendre son entreprise à GAZ METROPOLITAIN INC.et de cesser ses opérations et la révocation de ses droits de distribuer du gaz accordés par les cités de Sherbrooke et de Trois-Rivières respectivement.La Régie de l'électricité et du gaz tiendra une enquête publique relativement auxdites demandes à ses bureaux au 2100 rue Drummond, Montréal H3G 1X1, le 9 avril 1974 à dix heures de l'avant-midi.Montréal, ce 25e jour de février 1974.Le régisseur et secrétaire, 5627 l-o Denis Savignac.GAZ METROFO' II AIN, INC.and GAZ DU QUEBEC, INC.Application for an exclusive right to distribute gas within the cities of Sherbrooke and Trois-Rivières, P.Q.etc.Notice is hereby given that the Electricity and Gas Board has received from GAZ METROPOLITAIN INC., an application for an exclusive right to distribute gas within the cities of Sherbrooke and Trois-Rivières, P.Q, in the place and stead of GAZ DU QUEBEC INC.which company requests authority to sell its undertaking to GAZ METROPOLITAIN INC and cease its operations and the revocation of its rights to distribute gas granted by the cities of Sherbrooke and Trois-Rivières respectively.The Electricity and Gas Board will hold a public hearing in respect of the applications at its offices, 2100 Drummond St., Montreal H3G 1X1, on April 9, 1974 at 10 o'clock A.M.Montreal, this 25th day of February 1974.Denis Savignac, 5627l-o Controller and Secretary.Soumissions \u2014 Demandes de Ville de Boucherville Comté de Chambly Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Eugène McClish, greffier.Hôtel de ville, 500.rue Ri-yière-aux-Pins, Boucherville.comté de Chambly, P.Q.jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 19 mars 1974.pour Tenders \u2014 Requests for Town of Boucherville County of Chambly Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Eugène McClish, Town Clerk, at the Town Hall, 500 Rivière-aux-Pins Street, Boucherville, County of Chambly, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, March 19, 1974, for the purchase of a bond GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n° 9 1767 l'achat de $1,235,000 d'obligations de la ville de Boucherville, comté de Chambly, datées du 15 avril 1974 et remboursables en série du 15 avril 1975 au 15 avril 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement ley 15 avril et 15 octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 avril 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $1,235,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 04 1975.$ 24,000 15 04 1976.28,000 15 04 1977 .29,000 15 04 1978 .31.000 15 04 1979 .36,000 15 04 1980.38,000 15 04 1981.41.000 15 04 1982 .43,000 15 04 1983 .46,000 15 04 1984 .49,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde îeporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $219,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant ci-haut, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 avril 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 avril 1994 au montant de $219,000 comprend un solde de $118,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: Date Capital 15 04 1995.$ 8,000 15 04 1996.9,000 15 04 1997.10,000 15 04 1998.10,000 15 04 1999.11,000 issue of $1,235,000 for the Town of Boucherville, County of Chambly, dated April 15, 1974, and redeemable serially from April 15, 1975 to April 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on April 15th and October 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 15, 1974.Redemption table \u2014 SI ,235,000 \u2014 20 years Date Capital 15 04 1985.$ 52,000 15 04 1986 .56,000 15 04 1987 .62,000 15 04 1988 .66,000 15 04 1989.72.000 15 04 1990 .77,000 15 04 1991____.82,000 15 04 1992.88,000 15 04 1993.96,000 15 04 1994 .219,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $219,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of April 15,\" 1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of April 15, 1994 in the amount of $219,000 includes a balance of $118,000 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Date Capital 15 04 2000.$12,000 15 04 2001.13,000 15 04 2002.14,000 15 04 2003.15,000 15 04 2004.16,000 1768 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March J.1974.Vol- Wuis-Hémon Regional School Board, dated April GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉ3EC, 2 mm 1974, W5' année, n° 9 1771 nale Louis-Hémon, datées du 15 avril 1974 et remboursables en séries du 15 avril 1975 au 15 avril 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement les 15 avril et 15 octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera cale jlé à compter du 15 avril 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $2,200,000 \u2014 20 ans \tAnnée\t\tCapital 15\t04\t1975.\t.$ 43,000 15\t04\t1976.\t.47,000 15\t04\t1977.\t.51,000 15\t04\t1978.\t.56,000 L6\t04\t1979.\t.61,000 15\t04\t1980.\t.66,000 15\t04\t1981.\t.72,000 15\t04\t1982.\t.79,000 15\t1)4\t19S3.\t.86,000 15\t04\t1984.\t.93,000 La commission scolaire régionale Louis-Hémon se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 19 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $221,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 avril 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.15.1974 and redeemable serially from April 15, 1975 to April 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on April 15th and October 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 15, 1974.Redemption table \u2014 S2.200.000 \u2014 20 years \tDate\t\tCapital 15\t04\t1985.\t.$102,000 15\t04\t1986.\t.111,000 15\t04\t1987.\t.121,000 15\t(14\t1988.\t.132,000 15\t04\t1989.\t.144.000 15\t04\t1990.\t.156.000 15\t01\t1991.\t.171,000 15\t04\t1992.\t.186,000 15\t01\t1993.\t.202,000 15\t04\t1994.\t.221,000 The Louis-Hémon Regional School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Moreover, the following terms and conditions only will be considered : 1.1 to 10-year bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-ycar serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one paît and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds will not be for an amount less than $221,000, and if greater than the latter amount, the said surplus must only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of April 15, 1994.However, tenders will be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law. 1772 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol- 106, No.9 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 8221,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire régionale de Louis-Hémon s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 avril 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu de la résolution suivante: 29 août 1973 \u2014 82,200,000 \u2014 construction d'un complexe polyvalent à Mistassini.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue à 8 heures du soir, mercredi, le 20 mars 1974, École Polyvalente St-Félicien, Roberval, comté de Roberval, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Louis-Hémon (Comté de Roberval), ce 13 février 1974.Le directeur-général, André Perron.Bureau administratif, 930, boul.Sacré-Coeur, Dolbeau, Comté de Roberval, P.Q.Téléphone: 276-2010, code 418.56176-o La commission scolaire Vallée-de-Mistassini Siège social: 68, rue Savard, Mistassini, comté de Roberval.(P.Q.) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Claude Gagné, directeur-général.Bureau administratif.68, rue Savard, Mistassini, comté de Roberval, P.Q.G0W-2C0.jusqu'à 8.00 heures du soir, mardi, le 19 mars 1974, pour l'achat de $186,000 d'obligations pour la commission scolaire Vallée-de-Mistassini, datées du 15 avril 1974 et remboursables en série du 15 avril 1975 au 15 avril 1984 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement les 15 avril et 15 octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except it they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than 8221,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Louis-Hémon Regional School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon from and after April 15, 1974, without written authorization from the succcessful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: August 29, 1973 \u2014 82.200,000 \u2014 construction of a comprehensive school complex in Mistassini.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Wednesday, March 20, 1974.at 8K)0 o'clock p.m., at the St-Félicien Comprehensive School, Roberval, County of Roverval, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Louis-Hémon (County of Roberval), February 13, 1974.André Perron.Director-General.Administration Office.930 Sacré-Coeur Boulevard.Dolbeau, County of Roberval, P.Q.Telephone: 276-2010, code 418.56176 The Vallée-de-Mistassini School Board Head Office: 68 Savard Street.Mistassini, County of Roberval.P.Q.Public notice is hereby given that scaled tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Claude Gagné.Director-General, at the Administration Office.68 Savard Street, Mistassini.County of Roberval, (P.Q.), G0W-2C0, until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, March 19, 1974, for the purchase of a bond issue of $186,000 for the Vallée-de-Mistassini School Board, dated April 15, 1974, and redeemable serially from April 15, 1975 to April 15.1984 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%.nor more than 9%.payable semiannually on April 15th and October 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n° 9 1773 Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 avril 1974.Tableau d'amortissement \u2014 8186,000 \u2014 10 ans Date Capital 15 04 1975 .813,500 15 04 1976.14,500 15 04 1977.15,500 15 04 1978.16,000 15 04 1979.17.500 La commission scolaire de Vallée-de-Mistassini, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64) demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.On est prié de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire de Vallée-de-Mistassini s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 avril 1974.sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 23 août 1963 \u2014 8112.000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 20 novembre 1973 \u2014 $4.000 \u2014 frais de refinancement; 8 janvier 1974 \u2014 $70,000 \u2014 dépenses d'immobilisations 1965 à 1973.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue à 8.00 heures du soir, mardi, le 19 mars 1974.Bureau administratif.68 rue Savard.Mistassini.comte de Roberval.P.Q.G0W-2C0.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Mistassini (Comté de Roberval), ce 22 février 1974.Le directeur-général, Claude Gagné.Bureau administratif.68.rue Savard.Mistassini, (Roberval), P.Q.G0W-2C0.Téléphone: 276-0952, code 418.56237-o For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 15, 1974.Redemption table \u2014 $186,000 \u201410 years Date Capital 15 04 1980.$19,000 15 04 1981.20,500 15 04 1982 .22.000 15 04 1983.23.000 15 04 1984 .24,500 The Vallée-de-Mistassini School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.It is to be noted that the tenders are called for bonds redeemable as per the above table only, and that offers which might be made for short-term bonds will not be considered.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must lie accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Vallée-de-Mistassini School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after April 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.Tire said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: August 23, 1963 \u2014 $112,000 \u2014 loan renewal; November 20, 1973 \u2014 $4,000 \u2014 refinancing costs; January 8, 1974 \u2014 $70,000 \u2014 capital expenditures from 1965 to 1973.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held at 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, March 19, 1974, at the Administration Office.68 Savard Street, Mistassini, County of Roberval.P.Q.G0W-2C0.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Mistassini, (County of Roberval).February 22.1974.Claude Gagné, Director-General.Administration Office, 68 Savard Street, Mistassini, (Roberval).(P.Q.).G0W-2C0.Telephone: 276-0952, code 418.56237 1774 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 2.1974.Vol.100.So.9 Ville de Ste-.VIarthe-sur-le-I.ac Comté de Deux-Montagnes Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations >\u2022 seront reçues par le soussigné Roger Cofsky, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, 29X0, Chemin Oka.Ste-Marthe-sur-le-Lac.comté de Deux-Montagnes, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mercredi, le 20 mars 1974, pour l'achat de $183,500.d'obligations de la ville de Ste-Marthe-sur-le-Lac, comté de Deux-Montagnes, datées du 15 avril 1974 et remboursables en série du 15 avril 1975 au 15 avril 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement les 15 avril et 15octo-bre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 avril 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $183,500 \u2014 20 ans Date Capital 15 04 1975 .$ 2,000 15 04 1976 .2.500 15 04 1977 .3.000 15 04 1978 .3.000 15 04 1979 .3,500 15 04 1980 .3,500 15 04 1981 .3,500 15 04 1982 .4,000 15 04 19S3.4.500 15 04 1984 .5.000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées; 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3e Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $10,500.et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 avril 2014 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne Town of Ste.Marthe-sur-le-I.ac County of Two Mountains Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Roger Cofsky, Secretary-Treasurer, until 8:00o'clock p.m., on Wednesday.March 20, 1974, at the Town Hall, 2!»M) Oka Road.Ste.Marthe-sur-le-Lac, County of Two Mountains.P.Q., for the purchase of a bon,! issue of SI Mi.11HI for the Town of Ste.Marthc-sur-la-Lac, County of Two Mountains, dated April 15 1974 and redeemable serially from April 15, 1975, to April 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%.payable semiannually on April 15 and October 15 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 15, 1974.Redemption table \u2014 Î183.500 \u2014 20 years Date Capital 15 04 1985 .$ 2,500 15 04 1986 .2.500 15 04 1987 .2.500 15 04 1988 .3.000 15 04 1989 .3.000 15 04 1990 .3.500 15 04 1991 .4.000 15 04 1992 .4.000 15 04 1993 .5.000 15 04 1994 .119,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount lesss than $10,500, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of April 15.2014 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mars 1974.106' année, n' 9 1775 devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 avril 1994 au montant de $119,000 comprend un solde de 8114,000 renouvelable pour une période additionnelle de 20 ans, et échéant comme suit: Date Capital 15 04 1995 .8 2,500 15 04 1996 .2,500 15 04 1997 .3,000 15 04 1998 .3,000 15 04 1999 .3,500 15 04 2000 .3,500 15 04 2001 .4,000 15 04 2002 .4,500 15 04 2003 .4,500 15 04 2004 .5,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables a toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetalles par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à SI 19,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Ste-Marthe-sur-le-Lac s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 avril 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 101 \u2014 $65,000 \u2014 aqueduc et égouts; 111\u2014$53,500 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 112 \u2014 $18,900 \u2014 quote-part à l'incinérateur régional; 114-A \u2014 $27,100 \u2014 voirie; 118 \u2014 $19,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8 heures du soir, mercredi, le 20 mars 1974, Hôtel de Ville, 2980, Chemin Oka, Ste-Marthe-sur-le-Lac, comté de Deux-Montagnes, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ste-Marthe-sur-le-Lac (Comté de Deux-Montagnes), ce 20 février 1974.Le secrétaire-trésorier, Roger Cofsky.Hôtel de ville, 2980, Chemin Oka, Ste-Marthe-sur-le-Lac, (Deux-Montagnes), P.Q.Téléphone: 473-3105, code 514.56202-o of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of April 15, 1994 in the amount of $119,000 includes a balance of $114,000 renewable for an additional 20-year period, maturing as follows: Date Capital 15 04 2005 .$ 5,500 15 04 2006 .6,000 15 04 2007 .6,500 15 04 2008 .6,500 15 04 2009 .7,500 15 04 2010 .8,000 15 04 2011 .8,500 15 04 2012 .9,000 15 04 2013 .10.000 15 04 2014 .10,500 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in this tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $119.000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Ste.Marthe-sur-le-Lac agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after April 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 101 \u2014$65,000 \u2014 waterworks and sewers; 111\u2014$53,500 \u2014waterworks, sewers, roads; 112 \u2014 $ 18,900 \u2014 share i n cost of regional incinerator ; 114-A \u2014 $27,100 \u2014 roads; 118 \u2014 $19,000 \u2014 waterworks, sewers and roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held on Wednesday, March 20, 1974, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 2980 Oka Road, Ste.Marthe-sur-le-Lac, County of two Mountains.P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest nor any of the tenders.Ste.Marthe-sur-le-Lac, (County of Two Mountains), February 20, 1974.Roger Cofsky, Secretary-Treasurer.City Hall, 2980 Oka Road.Ste.Marthe-sur-le-Lac, Two Mountains, P.Q.Telephone: 473-3105, code 514.56202 1776 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.9 Commission scolaire régionale Louis-Fréchette Siège social : 30 ouest, rue Champagnat Lévis, comté de Lévis, P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Gilles Rail, directeur-général, jusqu'à 5 heures de l'après-midi, Centre Administratif, 30 ouest, rue Champagnat, Lévis, comté de Lévis, P.Q., G6V-2A5, et par après jusqu'à 8 heures du soir.École Polyvalente de Lévis (Salle de la bibliothèque), 55, rue des Commandeurs, Lévis, comté de Lévis, P.Q., lundi, le 18 mars 1974, pour l'achat de $3,430,000 d'obligations de la commission scolaire régionale Louis-Fréchette, datées du 15 avril 1974, et remboursables en série du 15 avril 1975 au 15 avril 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement les 15 avril et 15 octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 avril 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $3,430,000 \u2014 20 ans \tDate\tCapital 15\t04 1975 .\t.$108,000 15\t04 1976 .\t.117,000 15\t04 1977 .\t.128,000 15\t04 1978 .\t.140,000 15\t04 1979 .\t.152,000 15\t04 1980 .\t.166,000 15\t04 1981 .\t.181,000 15\t04 1982 .\t.197,000 15\t04 1983 .\t.214,000 15\t04 1984 .\t.234,000 La commission scolaire régionale Louis-Fréchette se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'Éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des Finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.The Louis-Fréchette Regional School Board Head Office: 30 Champagnat Street West, Levis, County of Levis, P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned.Gilles Rail.Director-General, at the Administration Centre, 30 Champagnat Street West, Levis, County of Lévis, P.Q., G6V-2A5, until 5:00 o'clock p.m.and thereafter until 8:00 o'clock p.m., at the Levis Comprehensive School (Library), 55 Commandeurs Street, Levis.County of Lévis, P.Q., on Mondav.March 18, 1974.for the purchase of a bond issue of $3,430,000 for the Louis-Fréchette Regional School Board, dated April 15, 1974, and redeemable serially from April 15, 1975 to April 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on April 15th and October 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 15, 1974.Redemption table \u2014 83,430,000 \u2014 20 years Date Capital 15 04 1985 .$118,000 15 04 1986 .129,000 15 04 1987 .140,000 15 04 1988 .153,000 15 04 1989 .167,000 15 04 1990 .181,000 15 04 1991 .198,000 15 04 1992 .216,000 15 04 1993 .235,000 15 04 1994 .256,000 The Louis-Fréchette Regional School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal there, of if required.Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n\" 9 1777 4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 8256,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 avril 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 8256.000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire régionale Louis-Fréchette s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 avril 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 11 juin 1973 \u2014 $2,550,000 \u2014 Construction d'un complexe polyvalent à Saint-Damien; 7 janvier 1974 \u2014 $880,000 \u2014' Coût excédentaire au 30 juin 1973.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 18 mars 1974, à 8 heures du soir.École Polyvalente de Lévis, (Salle de la bibliothèque), 55, rue des Commandeurs, Lévis, comté de Lévis, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Lévis (Comté de Lévis), ce 21 février 1974.Le directeur-général, Gilles Rail.Centre administratif, 30 ouest, rue Champagnat, Lévis, Comté de Lévis, Québec, G6V-2A5.Téléphone: 837-0241, code 418.56243-0 4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds will not be for an amount less than \u2014 $256.000.and if greater than the latter amount, the said surplus must only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of April 15, 1994.However, tenders will be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $256,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Louis-Fréchette Regional School Hoard agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon from the, and after April 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: June 11, 1973 \u2014 $2,550,000 \u2014 construction of a comprehensive school complex in St.Damien; January 7, 1974 \u2014 $880,000 \u2014 excess costs as at June 30, 1973.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Monday.March 18, 1974, at 800 o'clock p.m., at the Levis Comprehensive School, (Library), 55 Commandeurs Street, Levis, County of Levis, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Levis (County of Levis), February 21, 1974.Gilles Rail.Director General.Administration Centre, 30 Champagnat Street West, Levis (County of Levis), P.Q.Telephone: 837-0241, code 418.56243 1778 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.9 Commission scolaire régionale de la Mauricie Siège social : 390, 3e Avenue, Shawinigan-Sud.CP.580.Comté de Saint-Maurice, (P.Q.) Avis publie est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Jean-Louis Cloutier, directeur-général, jusqu'à 5.00 heures de l'après-midi, Centre Administratif, 390, 3e Avenue, Shawinigan-Sud, comté de Saint-Maurice, P.Q.G9N-6V7, et par après jusqu'à 8.00 heures du soir, Centre Administratif de la Commission scolaire de Shawinigan, 500, avenue Broadway, Shawinigan, comté de Saint-Maurice, (P.Q.).jeudi, le 21 mars 1974.pour l'achat de $1,169,000 d'obligations de la commission scolaire régionale de la Mauricie, datées du 15 avril 1974, et remboursables en série du 15 avril 1975 au 15 avril 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9% payable semi-annuellement les 15 avril et 15 octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 avril 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $1,169,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 04 1975.$ 25,000 15 04 1976 .27,000 15 04 1977.29,000 15 04 1978 .31,000 15 04 1979.34,000 15 04 1980 .34,000 15 04 1981.40,000 15 04 1982.44,000 15 04 1983.47,000 15 04 1984 .51,000 La commission scolaire régionale de la Mauricie se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'Education d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des Finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série I à 10 ans avec le solde a terme fixe 20 ans.The Mauricie Regional School Board Head Oflice: 390-3rd Avenue.Shawinigan-South P.O.Box 580, County of St.Maurice, P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Jean-Louis Cloulier, Director-General, on Thursday, March 21, 1974, until 5:00 o'clock p.m.at the Administration Centre, 390-3rd Avenue, Shawinigan-South, County of St.Maurice, P.Q., G9N-6V7, and thereafter until 8:00 o'clock p.m., at the Administration Centre of the Shawinigan School Board, 500 Broadway Avenue, Shawinigan, County of St.Maurice, P.Q., for the purchase of a bond issue of $1,169,000 for the Mauricie Regional School Board, dated April 15, 1974, and redeemable serially from April 15, 1975 to April 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less thaD 8% nor more than 9%, payable semiannually on April 15th and October 15th of each year.The rate of interest may be the same for the wbole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each différent rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes ODly, interest will be calculated as from April 15,1974.Redemption table \u2014 SI,169,000 \u2014 20 years Date Capital 15 04 1985.$ 55,000 15 04 1986 .60,000 15 04 1987 .64,000 15 04 1988 .69,000 15 04 1989 .75,000 15 04 1990 .81,000 15 04 1991.88,000 15 04 1992 .96,000 15 04 1993.104,000 15 04 1994.112,000 The Mauricie Regional School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974.106- année, n' 9 1779 4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $112,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 avril 1994.Cependant les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.I* capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $112.000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire régionale de la Mauricie s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 avril 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivants: 2 novembre 1972 \u2014 $815,000 \u2014 construction d'un complexe polyvalent à La Tuque; 3 janvier 1974 \u2014 $354,000 \u2014 dépenses d'immobilisations 1972-1973.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue jeudi, le 21 mars 1974, à 8.00 heures du soir.Centre Administratif de la commission scolaire Shawinigan, 500, avenue Broadwav, Shawinigan, comté de Saint-Maurice, (P.Q.).Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Shawinigan-Sud (Comté de Saint-Maurice), ce 21 février 1974.Le directeur-général, M.Jean-Louis Cloutieb.Centre Administratif.390, 3e Avenue, Shawinigan-Sud, Comté de Saint-Maurice.Québec, G9N-6V7 Téléphone : 536-2601, code 819.56236-0 4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-teim bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds will not be for an amount less than $112,000 and if greater than the latter amount, the said surplus must only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of April 15, 1994.However, tenders will be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $112,000 and I ln-said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to l%of the amount of the loan.The Mauricie Regional School Board agrees not to bring outnew bondson the Canadian Market within the sixty days upon from and after April 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: November 2, 1972 \u2014 $815,000 \u2014 Construction of a comprehensive school in La Tuque; January 3, 1974 \u2014 $354,000 \u2014 capital expenditure for 1972-1973.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Thursday, March 21, 1974, at 8:00 o'clock p.m.at the Administration Centre of the Shawinigan School Board, 500 Broadway Avenue, Shawinigan, County of St.Maurice, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Sbawinigan-South (County of St.Maurice), Fe-burary21,1974.Mr.Jean-Louis Cloutier, Director-General.Administration Centre, 390-3rd Avenue, Shawinigan-South, County of St.Maurice, Québec, G9N-6V7 Telephone: 536-2601, code 819.56236 1780 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.9 Ventes par Shérifs Sheriff's Sales AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.HAUTERIVE HAUTERIVE Canada \u2014 Province de Québec District de Hauterive Cour Supérieure, I T ES COMMISSAIRES DÉCO-No 14678.< *-> LE POUR LA MUXICLPA-l LITÉ SCOLAIRE DE MANICOUAGAN, demandeur, ts GEORGES DESBIENS, défendeur.Une maison seulement construite sur une partie du lot 41, Rang 1, Ragueneau, Canton Ragucncau.Ladite partie du lot appartenant à Mme Narcisse Bernatchcz et la maison seulement étant la propriété du défendeur.Pour être vendu au bureau du registrateur de la première division d'enregistrement de Saguenay, au Palais de justice de Baie-Comeau, MARDI, le VINGT-TROISIÈME jour d'AVRIL 1974 à ONZE heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif adjoint, Charlotte Bergeron.Baie Bomeau, ce 2 mars 1974.56253-0 Canada \u2014 Province of Québec District of Hauterive Superior Court, ( THE SCHOOL COMMISSION-No.14678 < 1 NERS FOR THE SCHOOL \\ MUNICIPALITY OF MANICOUAGAN, plaintiffs, r* GEORGES DESBIENS, de-fendant.A house only, built on a part of lot 41, Range 1, Ragueneau, Township of Ragueneau.Said part of lot belonging to Mrs.Narcisse Bernatchez and the house alone being the property of the defendant.To be sold at the office of the registrar for the First registration division of Saguenav, in the Court House of Baie-Comeau, on TUESDAY, the TWENTY-THIRD day of APRIL, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Charlotte Bergeron, Assistant Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Baie Comeau, this 2nd of March, 1974.56253 JOLIETTE Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Joliette No ( \\/ILI.E DE REPENTIGNY, deman-18,520.< V deresse, is DAME DOMENTCO I ROSSI, 54, avenue Becket, Toronto, Ontario, défenderesse.« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 41-76, lot de forme irrégulière borné en front au sud par le lot 41-51 (rue), au nord-ouest par le lot 41-75, au nord-est par partie du lot 41-78 et à l'est parle lot 41-77; mesurant 118 pieds et 21 centièmes de pied (118.21') le long d'un arc de cercle de 149 pieds et 41 centièmes de pied (149.41') de rayon en front au sud, 101 pieds et 57 centièmes de pied (101.57') au nord-ouest, 38 pieds et 36 centièmes de pied (38.36') au nord-est, 89 pieds et 84 centièmes de pied (89.84') à l'est, contenant en superficie 7,508 pieds et 11 centièmes de pied carrés (7.508.11') mesures anglaises des plan et livre de renvoi officiels de Notre-Dame-de-l'Assomption-de-Repenti-gny.JOLIETTE Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Joliette No.18,520.fendant.I TOWX OF REPENTIGNY, plaintiff, .< A r* MRS.DOMENTCO ROSSI, 54 ' Becket Avenue, Toronto, Ontario, de- \"An immoveable known and described as being lot 41-76, of irregular form, bounded in front, on the south, by lot 41-51 (street), on the northwest by lot 41-75, on the northeast by part of lot 41-78 and on the east by lot 41-77; measuring one hundred eighteen and twenty-one hundredths feet (118.21') along an arc of a circle having a radius of one hundred forty-nine and forty-one hundredths feet (149.41') in front on the south, one hundred one and fifty-seven hundredths feet (101.57') on the northwest, thirty-eight and thirty-six hundredths feet (38.36') on the northeast, eighty-nine and eighty-four hundredths feet (89.84') on the east, and covering an area of seven thousand five hundred eight and eleven hundredths square feet (7,508.11' sq.ft).English measure, on the official plan and in the book of reference of Notre-Dame-de-l'Assomption-dc-Rcpcnti-gnj'\" GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, g mars 1974, 106' année, n° 9 1781 Pour être vendu au bureau de la division d'enregistrement de l'Assomption, à l'Assomption, district de Joliette, MARDI, le VINGT-TROISIÈME jour d'AVRIL 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Le shérif, Bureau du Shérif, Christian Roy.Joliette, le 22 février 1974.56267-0 MONTMAGNY Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montmagny ( /COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR No 12-151.< v-' LA VIE LA SAUVEGARDE, cor- t poration légalement constituée ayant son siège social au 152 est, rue Notre-Dame, en les cité et district de Montréal, Que., demanderesse, vs JEAN-GUY BERNIER, entrepreneur-électricien, domicilié à Cap St-Ignace, comté de Montmagny, Que., défendeur, et CLE MARTINEAU ÉLECTRIQUE LTÉE, corporation légalement constituée ayant son siège social au 860 est, rue Du Roi, Québec, Que., mise en cause, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Montmagny, mis en cause.« Un terrain connu et désigné comme étant le numéro un, subdivision du lot originaire numéro cent quatre-vingt-huit (188-1) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour la paroisse de Cap St-Ignace, comté de Montmagny, borné vers le nord-ouest par la route 2 (actuelle), vers le nord-est par une partie du lot 188, vers le sud-est par le lot 188-2 et une partie du lot 188, vers le sud-ouest par le lot 190, mesurant cent trois pieds (103') au nord-ouest, cent quatre-vingt-quatorze pieds et cinq dixièmes de pied (194.5') au nord-est, cent cinq pieds et trois dixièmes de pied (105.3') au sud-est et cent quatre-vingt-neuf pieds (189') au sud-ouest.Pour être vendu au bureau de la division d'enregistrement de Montmagny, au Palais de Justice de Montmagny, JEUDI, le QUATRIÈME jour d'AVRIL 1974, à TROIS heures de l'après-midi.Montmagny, 22 février 1974.Le shérif, 56238-0 Jean-Paul Tremblay.MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( \"DANQUE D'ÉPARGNE DE No 05-007206-73.-J ¦£> LA CITÉ ET DU DISTRICT DE MONTRÉAL, demanderesse, rersusTORENO HOMES INC.ET AL., défenderesses et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Montréal, et al., mis en cause.To be sold at the office for the l'Assomption Registration Division in l'Assomption, District of Joliette, on TUESDAY, the TWENTY-THIRD day of APRIL, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Christian Roy, Sheriff's Office, Sheriff.Joliette, February 22, 1974.56267 MONTMAGNY Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montmagny l COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR No.12-1S1X LA VIE LA SAUVEGARDE, a ' corporation legally incorporated having its head office located at 152 Notre-Dame Street East, in the Citv and District of Montreal, Que., plaintiff, vs JEAN-GUY BERNIER, electrical contractor, domiciled in Cap St.Ignace, County of Montmagny, P.Q., defendant, and CIE MARTINEAU ÉLECTRIQUE LTÉE, a corporation legally incorporated having its head office located at 860 Du Roi Street East, Québec, Que., mise en cause, and THE REGISTRAR for the Montmagny Registration Division, mis en cause.\"A piece of land known and described as number one, subdivision of original lot number one hundred eighty-eight (188-1) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Cap St.Ignace, County of Montmagny, bounded towards the northwest by (present) Highway 2, towards the northeast by a part of lot 188, towards the southeast by lot 188-2 and a part of lot 188, towards the southwest by lot 190, measuring one hundred three feet (103') on the northwest, one hundred ninety-four and five tenths feet (194.5') on the northeast, one hundred five and three tenths feet (105.3') on the southeast and one hundred eighty-nine feet (189') on the southwest.To be sold at the office of the Montmagny Registration Division, in the Montmagny Court House, on THURSDAY, the FOURTH day of APRIL, 1974, at THREE o'clock in the afternoon.Montmagny, February 22, 1974.Jean-Paul Tremblay, 56238 Sheriff.MONTREAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( THE MONTREAL CITY AND No.05-007206-73.< -1 DISTRICT SAVINGS \\ BANK, plaintiff; versus TORENO HOMES INC.ET AL, defendants and THE REGISTRAR for the Registration Division of Montreal, et al, mis en cause. 1782 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.9 * Un certain emplacement ayant front sur la rue Provence en la ville de Saint-Léonard (Québec), et composé des lots suivants: 1.Le lot numéro trois cent quarante-deux de la subdivision du lot originaire numéro trois cent quatre-vingt-cinq (385-342) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Sault-au-Récollet, mesurant 50.0 pieds de largeur sur 85.0 pieds de profondeur.2.Le lot numéro un de la subdivision du lot numéro trois cent quarante-trois de la subdivision du lot originaire numéro trois cent quatre-vingt-cinq (385-343-1) auxdits plan et livre de renvoi officiels, mesurant 7.0 pieds de largeur sur 85.0 pieds de profondeur.Les* dimensions citées ci-dessus sont en mesures anglaises et plus ou moins.Avec un immeuble dessus en voie de construction portant les numéros civiques 8883, 8885, 8887, 8889 et 8889A, rue de Provence, et dont le mur nord-ouest est mitoyen.Avec le droit d'avoir une porte de garage, deux fenêtres et deux galeries donnant sur la propriété adjacente au nord-ouest, connue comme étant le lot numéro 385-343-2 et le droit pour ladite propriété adjacente d'avoir une porte de garage, une fenêtre et un balcon donnant sur la propriété présentement hypothéquée, même si les immeubles sont plus près de la ligne de division que ne le permet la loi; une servitude de vue réciproque étant créée à cet effet par le présent emprunteur qui est le propriétaire des deux immeubles.Ainsi que le tout se trouve actuellement avec tous ses droits, membres et circonstances y rattachés et avec toutes les servitudes actives et passives y rattachées, le tout sans exception ni réserve d'aucune sorte.» Pour être vendu au bureau du Shérif, Palais de Justice de Montréal, 10, rue Craig est, 10e étage, chambre 56, le TROISIÈME jour de mois d'AVRIL 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 18 février 1974.56230 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Montréal No: 02-045 288-73 l JOSEPH ELLE LTEE.de-C.S.M.: 18-000 138-744-C J mandeur, vs Dame CHAR-l LES HENRI PILON, défenderesse.« Un emplacement ayant front sur la iue Tupper, dans le Quartier St-Antoine, en la Cité de Montréal, et mesurant vingt-quatre pieds par quatre-vingt-quatorze pieds (24' x 94') et composé de: 1.Une partie du lot numéro trente-trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro mille six cent vingt-cinq « J » (1625.1-Ptie 33) au cadastre officiel du Quartier St-Antoine, mesurant sept pieds de largeur (7) par toute la profondeur dudit lot et étant bornée en \"That certain emplacement fronting on Provence Street in the City of St.Léonard, Province of Québec, composed of : (1) Lot number three hundred and forty-two of the subdivision of original lot number three hundred'and eighty-five (385-342) on the official plan and book of reference of the parish of Sault-au-Récollet, measuring 50.0 feet in width by 85.0 feet in depth.(2) Lot number one of the subdivision of lot number three hundred and forty-three of the subdivision of original lot number three hundred and eighty-five (385-343-1) on the said official plan and book of reference, measuring 7.0 feet in width by 85.0 feet in depth.All the above measurements are English Measure and more or less.With the building thereon in the course of construction bearing civic numbers 8883, 8885, 8887, 8889 and 8889A Provence Street, whereof the northwesterly wall is mitoyen.With the right to have one garage door, two windows and two galleries overlooking the adjoining property to the northwest known as lot number 385-343-2 and for said adjoining property to have the right to have one garage door, one window and one gallery overlooking the property herein hypothecated, even though the same are nearer to the division line between said two properties than that allowed by law; a reciprocal servitude of right of view to that effect being hereby created by the Borrower herein as being the owner of both properties.As the said property now subsists with all its rights, members and appurtenances thereunto belonging and with all active and passive servitudes thereto attached, the whole without exception or reserve of any kind.\" To be sold at the Sheriff's Office, Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th floor.Room 56, on the THIRD day of APRIL 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St.Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, February 18, 1974.56230-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Montreal No.02-045 288-73 t JOSEPH ELIE LTEE, S.C.M.: 18-000 138-744< J plaintiff, vs Mrs.CHAR-l LES HENRI PILON, defendant.\"An emplacement fronting on Tupper Street in St.Antoine Ward, in the City of Montreal, and measuring twenty-four feet by ninety-four feet (24' x 94') and comprising: 1.A part of lot number thirty-three (33) of the official subdivision of original lot number one thousand six hundred and twenty-five \"J\" (1625J-Pt 33) on the official cadastre for St.Antoine Ward, measuring seven feet (7') in width by the whole depth of said lot and GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n' 9 1783 front par la rue Tupper, en arrière par le lot numéro 1625J-36-6, d'un côté au sud-ouest par le résidu du lot numéro 1625J-33 et au nord-est par le lot numéro 1625J-Ptie 34 ci-après décrite; 2.Une partie du lot numéro trente-quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro mille six cent vingt-cinq « J » (1625J-Ptie 34) au cadastre officiel du Quartier St-Antoine, mesurant dix-sept pieds de largeur (17') par toute la profondeur dudit lot et étant bornée en front par la rue Tupper, en arrière par le lot numéro 1625J-36-7, d'un côté au sud-ouest par le lot numéro 1625J-Ptie 33 ci-haut décrite et au nord-est par le résidu du lot numéro 1625J-34, audit cadastre officiel du Quartier St-Antoine.3.Une partie des lots numéros six et sept de la subdivision du lot originaire numéro trente-six de la resubdivision officielle du lot originaire numéro mille six cent vingt-cinq « J » (1625J-36-Pties 6 et 7) au cadastre officiel du Quartier St-Antoine, ladite partie de lot numéro 1625J-36-6 mesurant sept pieds de largeur dans ses lignes nord-ouest et sud-est et trois pieds de profondeur dans ses lignes nord-est et sud-ouest et étant bornée au sud-est par le lot numéro 1625J-33, au nord-ouest par le lot 1625J-36, au nord-est par le lot numéro 1625J-36-7 et au sud-ouest par le résidu du lot numéro 1625J-36-6 audit cadastre; et ladite partie de lot numéro 1625J-36-7 mesurant dix-sept pieds de largeur dans ses lignes nord-ouest et sud-est et trois pieds de profondeur dans ses lignes nord-est et sud-ouest et étant bornée au sud-est par le lot numéro 1625J-34, au nord-ouest par le lot numéro 1625J-36, au sud-ouest par le lot numéro 1625J-36-6, au nord-est par le résidu du lot numéro 1625J-36-7 audit cadastre officiel du Quartier St-Antoine.Avec propriété dessus érigée et portant les numéros civiques 1821-23-25 de la rue Tupper, dans le Quartier St-Antoine en la Cité de Montréal.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice, en la Ville de Montréal, 10 est rue Craig, 10e étage, chambre 56, le QUATRIÈME jour d'AVRIL 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 18 février 1974.56229-0 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal { T A BANQUE D'ÉPARGNE No 05-007207-73.< ^ DES CITÉ ET DISTRICT ST-ROMUALD, société No 200-05-000020-74 J régie par la Loi des caisses ' d'épargne et de crédit ayant son siège social au 1184.rue Commerciale, à St-Romuald, P.Q.vs LOUIS-MARIE LAPLANTE.domicilié et résidant au 11, rue du Collège, à St-Romuald, district de Québec, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Lévis, mis en cause.« Les lots numéros cent quatre et cent cinq, tous deux subdivisés du lot originaire numéro trois cent soixante-cinq (365-104 et 365-105) du cadastre officiel pour la paroisse de St-Romuald d'Etchemin, comté de Lévis.Il faut distraire de ces immeubles, la partie de terrain appartenant à Paul-Émile Dumas, mesurant vingt-sept pieds (27') par soixante-six pieds sept dixièmes (66.7 ) le tout mesure anglaise, le tout tel que mentionné dans un acte de vente de J.Raymond Forgucs à Paul-Émile Dumas, passé devant Me Ernest Bergeron, notaire, le vingt-cinq (25) octobre mil neuf cent soixante-neuf (1969) et enregistré au bureau d'enregistrement de Lévis, le vingt-huit (28) du même mois, de la même année, sous le numéro 156,084.Fieri Facias de Terris Québec, to wit: / T A BELLE CONSTRUCTION Superior Court,) *-* INC., a corporation legally in-Arthabaska, \\ corporated, having its principal place No.4033.\\ of business in Victoriaville, in the Judicial District of Arthabaska.vs J.B.SPORTS PROMOTION INC., a corporation legally incorporated, having its head office in Victoriaville, in the Judicial District of Arthabaska, and LE CIRCUIT QUÉBEC STE.CROIX INC., a corporation legally incorporated, having its head office in Victoriaville.in the Judicial District of Arthabaska.and MRS.GERMAINE MO-RIN, residing in Victoriaville, in the Judicial District of Arthabaska.and Me WILFRID DESRUISSEAUX, in his capacity as Registrar at the office of the Lotbinière Registration Division, mis en cause.\"Certain immoveables located in the Parish of Ste.Croix, County of Lotbinière.north of Provincial Highway number 3, or Marie-Victorin Road, and known as being lots numbers one hundred seventy-five - one (175-1) (subdivision one of lot number 175), one hundred seventy-one - one (171-1) (Subdivision one of original lot 171) and one hundred sixty-nine - one (169-1) (Subdivision one of original lot number 169) on the official cadastre for the Parish of Ste.Croix, Lotbinière Registration Division; appurtenances and dependencies as the whole now subsists.\" To be sold at the Lotbinière Registry Office, in Ste.Croix, County of Lotbinière.on the FIFTH day of the month of APRIL.1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, February 25, 1974.56250 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: //BAISSE POPULAIRE DE Superior Court, ) V-< ST-ROMUALD, a credit No.200-05-000020-74\\ union governed by the Savings ' and Credit Unions Act, having its head office at 1184 Commerciale Street, in St.Ro-muald, P.Q., vs LOUTS-MARIE LAPLANTE, domiciled and residing at 11 Du Collège Street, in St.Romuald, District of Québec, and THE REGISTRAR for the Levis Registration Division, mis en cause.Lots numbers one hundred and four and one hundred and five, both subdivisions of original lot number three hundred sixty-five (365-104 and 365-105) on the official cadastre for the Parish of St.Romuald-d'Etchemin, County of Levis.To be withdrawn from said immoveables, the piece of land belonging to Paul-Émile Dumas, measuring twenty-seven feet (27') by sixty-six and seven tenths feet (66.7'), the whole English measure, the whole as mentioned in a deed of sale by J.Raymond Forgues to Paul-Émile Dumas, executed before Me Ernest Bergeron, notary, on the twenty-fifth (25th) of October, one thousand nine hundred sixty-nine (1969) and registered at the Levis Registry Office, on the twenty-eighth (28th) of same month, same year, under number 156,084. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1974, 106' année, n\" 9 1787 Il faut distraire aussi de ces immeubles une lisière de terrain appartenant à Jean-Claude Legendre, mesurant cinquante pieds (50') anglais de front, sur la rue du Collège, sur toute la profondeur desdits lots, le tout tel que mentionné dans un acte de vente de J.Raymond Forgues à Jean-Claude Legendre, passé devant Me Aimé Demers, notaire, le dix (10) août mil neuf cent soixante-cinq (1965) et enregistré au bureau d'enregistrement de Lévis, le treize (13) du même mois, de la même année, sous le numéro 140,611.Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendus au bureau d'enregistrement de Lévis, 113, St-Georges ouest, Lévis, le HUITIÈME jour du mois d'AVRIL 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 25 février 1974.56252-o To be n ithdrawn also from said immoveables a strip of land belonging to Jean-Claude Legendre, measuring fifty feet (50') in front, English measure, on Du Collège Street, by the whole depth of said lots, the whole as mentioned in a deed of sale by J.Raymond Forgues to Jean-Claude Legendre, executed before Me Aimé De-mers, notary, on the tenth (10th) of August one thousand nine hundred sixty-five (1965) and registered at the Levis Registry Office on the thirteenth (1.3th) of same month, same year, under number 140,611.The whole with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Levis Registry Office, 113 St.Georges West, Levis, on the EIGHTH day of the month of APRIL, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, February 25, 1974.56252 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: / JOSEPH GRAVEL, faisant affai-Cour Provinciale.J J res sous le nom de Trottoirs & No 81-886.J Chaînes du Québec enr.32, rue { Pichette, Château-Richer, P.Q.vs WILLIAM DOUCET, domicilié à 70, boulevard No 15, St-Tite-des-Caps.« Une terre située en la paroisse de St-Tite-des-Caps, formant la moitié du nord-est du lot connu et désigné sous le numéro (ptie N.E.102) pour la paroisse de St-Tite, la moitié mesurant deux (2) arpents et un quart 14 de largeur sur trente (30) arpents et sept (7) perches de profondeur, borné au nord-ouest par partie du lot 103 appartenant à Ovila Rodgers au sud par la ligne de concession, au nord-est par le lot 103 et au sud-ouest par l'autre moitié du lot 102.Avec bâtisses dessus construites sur ledit lot (102) circonstances et dépendances.» « Un immeuble situé en la paroisse de St-Tite-des-Caps, formant le lot connu et désigné sous le numéro (103-1) de la subdivision du lot originaire cent trois (103) sur le plan et dans le livre de renvoi du cadastre de la paroisse de St-Tite, division d'enregistrement de Montmorency, mesurant 395' en front du chemin royal et 395' de largeur dans la ligne sud-est sur une profondeur de 1000' dans la ligne sud-ouest et au nord-est borné vers le nord-est par le chemin royal (rte 15) vers le nord-est par le lot 104 non-subdivisé, vers le sud-est et le sud-ouest par des parties non subdivisées du lot 103, le tout avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendus au bureau d'enregistrement de Montmorency, à 8032, Royale, Château-Richer, comté Montmorency, le QUATRIÈME jour du mois d'AVRIL 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 25 février 1974.56251-0 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: / JOSEPH GRAVEL, carrying on Provincial Court, J J business under the name of No.81-886.J Trottoirs & Chaînes du Québec enr., lat 32 Pichette Street, Château-Richer, P.Q.vs WILLIAM DOUCET, domiciled at 70 Boulevard No.15, St.Tite-des-Caps.\"A farm located in the parish of St.Tite-des-Caps, comprising the northeast half of the lot known and described as number (N.E.Pt.102) for the parish of St.Tite, said half measuring two (2) and one fourth (}4) arpents in width by thirty (30) arpents and seven (7) rods in depth, bounded on the northwest by that part of lot 103 belonging to Ovila Rodgers, on the south by the concession line, on the northeast by lot 103 and on the southwest by the other half of lot 102.With the buildings erected thereon (said lot 102), appurtenances and dependencies.\" \"An immoveable located in the Parish of St.Tite-des-Caps, comprising the lot known and described as number (103-1) of the subdivision of original lot one hundred and three (103) on the plan and in the book of reference of the cadastre for the Parish of St.Tite, Montmorency Registration Division, measuring 395' in front on Royal Road and 395' in width on the southeast line by 1000' in depth on the southwest and the northeast lines, bounded towards the northeast by Royal Road (Highway 15), towards the northeast by lot 104 non subdivided, towards the southeast and the southwest by non subdivided parts of lot 103, the whole with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Montmorency Registry Office, 8032 Royale, Château-Richer, County of Montmorency, on the FOURTH day of the month of APRIL, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, February 25, 1974.56251 1788 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 197A, Vol.100, No.9 RIMOUSKI Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Districts de Rimouski et Québec Cour Supérieure : I V\"EY MORTGAGE CORP.LTD., No 4004.\\ -IX.corps politique et incorporé, ' ayant son bureau chef et principale place d'affaires, dans les cité et district de Montréal, demanderesse, es GAÉTAN LEVASSEUR, comptable, anciennement de la paroisse I,es Boules, district de Rimouski, présentement domicilié au 10575 rue Bélair, dans la Cité de Pierrefonds, district de Montréal, défendeur.« Partie des lots numéros soixante et onze et soixante-douze au cadastre officiel de la paroisse de l'Assomption-de-Notre-Dame, canton McNeider, premier rang, mesurant quatre-vingt-dix pieds de largeur est-ouest sur la profondeur qu'il peut y avoir entre le fleuve St-Laurent au nord et la route nationale au sud, bornée à l'est à Michel Giffard et à l'ouest à Léandre Brochu, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Un emplacement mesurant, mesure anglaise, soixante-cinq pieds et demi (65.5') de front sur la profondeur qu'il peut y avoir de la route nationale au fleuve St-Laurent, borné au nord, par le fleuve St-Laurent, à l'est par la propriété d'Alphonse Ratté, au sud par la route nationale, et à l'ouest par l'emplacement ci-dessus décrit, connu et désigné comme étant partie du lot soixante-douze (P-72) du cadastre officiel de la paroisse de l'Assomption-de-Notre-Dame, canton McNeider, avec bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances.Partie des lots numéros soixante-treize et soixante-quatorze (73 et 74-pties) au cadastre officiel pour la paroisse de l'Assomption-de-Notre-Dame, canton McNeider, mesurant environ soixante-douze pieds de largeur est-ouest sur la profondeur qu'il peut y avoir entre le fleuve St-Laurent au nord et la route nationale au sud, bornée au nord par le fleuve St-Laurent, à l'est à Jean-Wilfrid Turcotte, au sud à la route nationale et à l'ouest à Michel Giffard, tel que le tout se trouve actuellement, circonstances et dépendances.» Pour être vendues au bureau d'enregistrement de Matane, Palais de Justice, Ville de Matane, le TROISIÈME jour d'AVRIL 1974, à DEUX heures de l'après-midi.Le député shérif.Bureau du Shérif.Jacques Martin.Rimouski, 25 février 1974.56l63-o RIMOUSKI Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Districts of Rimouski and Québec Superior Court:): T/^EY MORTGAGE CORP.LTD., No.4004.\\ body politic and corporate, ' having its head office and principal place of business in the City and District of Montreal, plaintiff, vs GAÉTAN LEVASSEUR, accountant, formerly of the Parish of Les Boules, District of Rimouski, now domiciled at 10575 Bélair Street, in the City of Pierrefonds, District of Montreal, defendant.\"Part of lots numbers seventy-one and seventy-two on the official cadastre for the Parish of l'Assomption-de-Notre-Dame, Township of McNeider, First Range, measuring ninety feet in width from east to west by the depth that may be measured from the St.Lawrence River on the north and the National Highway on the south; bounded on the east by Michel Giffard and on the west by Léandre Brochu, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.An emplacement measuring sixty-five and one-half feet (65.5') in front, English measure, by the depth that exists between the National Highway and the St.Lawrence River; bounded on the north by the St.Lawrence River, on the east by the property belonging to Alphonse Ratté, on the south by the National Highway, and on the west by the emplacement hereinabove described, known and described as being part of lot seventy-two (Pt.72) on the official cadastre for the Parish of l'Assomption-de-Notre-Dame, Township of McNeider, with a building erected thereon, appurtenances and dependencies.Part of lots numbers seventy-three and seventy-four (73 and 74-Pts.) on the official cadastre for the Parish of l'Assomption-de-Notre-Dame, Township of McNeider, measuring about seventy-two feet in width from east to west by the depth contained between the St.Lawrence River on the north and the National Highway on the south; bounded on the north by the St.Lawrence River, on the east by Jean-Wilfrid Turcotte, on the south by the National Highway and on the west by Michel Giffard, whole as it now subsists, with appurtenances and dependencies.\" To be sold in the Matane Registry Office, at the Court House in the Town of Matane, on the THIRD day of APRIL, 1974, at TWO o'clock in the afternoon.Jacques Martin, Deputy Sheriff's Office, Deputy Sheriff.Rimouski, February 25, 1974.56163-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mars 1974.106' année, n' 9 1789 TERREBONNE Fieri Facias de Terril Canada \u2014 Province de Québec District de Terrebonne Cour Supérieure, ( OOCIÉTÉ CENTRALE D'HY-No 64,688.< O POTHEQUES ET DE LOGE-l MENT, corps politique dûment incorporé en vertu de la Loi fédérale, ayant un bureau d'affaires à Montréal, district de Montréal, demanderesse, rs LES HÉRITIERS LÉGAUX DE GREGG KILDOW, ayant une résidence autrefois à 805, boul.Ste-Thérèse-Ouesl, à Ste-Tbérèse-Ouest, des comté et district de Terrebonne, défendeurs.L'immeuble ci-après désigné et en la possession des défendeurs, à savoir: « Un emplacement ayant front sur le boulevard Ste-Thérèse-Ouesl, dans la municipalité de Ste-Thérèse-Ouest, connu et désigné sous le lot numéro quatre-vingt-huit de la subdivision du lot originaire numéro cent un et sous le lot numéro cinquante-neuf de la subdivision du lot originaire numéro cent deux (101-88, 102-59) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Thérèse-de-Blainville, division d'enregistrement de Terrebonne.Borné comme suit: Au nord: par le lot numéro 181-89.À l'est: par le lot 101-2 (boul.Ste-Thérèse-Ouest).À l'ouest: par les lots numéros 101-161, 102-126.Au sud: par les lots numéros: 101-87,102-58.Cedit emplacement est composé comme suit: a) Lot numéro: 101-88 Mesurant cent pieds (100) dans la ligne nord, cinquante pieds (50) dans la ligne est le long d'un arc de cercle engendré par un rayon de 1,179.48 pieds, quatre-vingt-deux pieds et dix-neuf centièmes de pied (82.19) dans la ligne sud, quarante-deux pieds et six centièmes de pied (42.06) dans la ligne sud-ouest, dix-sept pieds et soixante-seize centièmes de pied (17.76) dans la ligne ouest, le long d'un arc de cercle engendré par un rayon de 1,279.48 pieds.Contenant en superficie quatre mille huit cent soixante-quatre pieds carrés.6) Lot numéro: 102-59 Mesurant quarante-deux pieds et six centièmes de pied (42.06) dans la ligne nord-est, dix-sept pieds et quatre-vingt-un centièmes de pied (17.81) dans la ligne sud, trente-six pieds et quarante-huit centièmes de piep (36-48) dans la ligne ouest le long d'un arc de cercle engendré par un rayon de 1,279.48 pieds.Contenant en superficie trois cent quarante-huit pieds carrés (348).Avec une maison à deux étages portant les numéros civiques 805 et 807, boulevard Ste-Thérèse-Ouest, dont le mur sud de ladite maison érigée sur les lots numéros 101-87 et 102-58 du même cadastre.TERREBONNE Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Terrebonne Superior Court, ( CENTRAL MORTGAGE AND No.64,688.< ^ HOUSING CORPORATION, t duly incorporated according to Federal Law, having an office in the City and District of Montreal, plaintiff, rs the LEGAL HEIRS OF GREGG KILDOW, formerly residing at 805 Ste.Thérèse Boulevard Wesl, CouDty and District of Terrebonne, defendants.The immoveable hereinafter described and in the possession of the defendants, to nit: \"An emplacement fronting on Ste.Thérèse Boulevard West in the City of Ste.Thérèse West, known and described under lot number eighty-eight of the subdivision of original lot number one hundred and one and under lot number fifty-nine of the subdivision of original lot number one hundred and two (101-88, 102-59) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste.Thérèse-de-Blainville, Terrebonne Registration Division.Bounded as follows: Towards the north: by lot 181-89.Towards the cast: by lot 101-2 (Ste.Thérèse Boulevard West).Towards the west: by lots 101-161 and 102-126.Towards the south: by lots 101-87 and 102-58.Said emplacement comprises the following: (a) Lot 101-88 Measuring one hundred feet (100) on its north line, fifty feet (50) on the east line along an arc of a circle having a radius of 1,179.48 feet, eighty-two and nineteen hundredths feet (82.19) on the south line, forty-two and six hundredths feet (42.06) on the southwest line, seventeen and seventy-six hundredths feet (17.76) on the west line along an arc of a circle having a radius of 1,279.48 feet.Covering a surface area of four thousand eight hundred and sixty-four square feet.(6) Lot 102-59 Measuring forty-two and six hundredths feet (42.06) on the northwest line, seventeen and eigbty-one hundredths feet (17.81) on the south line, thirty-six and fortj-eight hundredths feet (36.48) on the west line along an arc of a circle having a radius of 1,279.48 feet.Covering a surface area of three hundred forty-eight square feet (348).With a two-story bouse bearing civic numbers 805 and 807 Ste.Thérèse Boulevard West, the south wall of the said house being erected on lots 101-87 and 102-58 of same cadastre. 1790 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, MA, Vol.106, No.9 Ainsi que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées auxdits immeubles et notamment sujet à la convention de servitudes consentie sous seing privé par les Immeubles Pelletier Ltée et al à Public Fuel Transmission systems Ltd., en date du vingt-septième jour du mois d'octobre mil neuf cent soixante-cinq (1965) tel qu'il appert d'un acte de convention préparé par Me Robert Benson, avocat, de Montréal, affecté et hypothéqué en faveur de la demanderesse depuis la date du présent jugement, jusqu'à concurrence de la somme de $24,454.81 avec intérêts à 7% l'an depuis le 21 mai 1971.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté des Deux-Montagnes, situé à 149, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, P.Q., JEUDI, le VINGT, HUITIÈME jour de MARS 1974, à DEUX heures de l'après-midi.Bureau du Shérif, Le shérif, Saint-Jérôme, Jean-Louis Muib.le 15 février 1974.56234-o Errata Dans l'avis publié dans la Gazelle officielle du Québec en date du 15 décembre 1973, No 50, page 7457 il faudrait lire: Dans la municipalité de la paroisse de Saint-Sauveur à la place de Morin Heights.Le secrétaire-général.56159-0 Roch Bergeron, ingénieur.POITRAS & LEVESQUE CONSTRUCTION LTD.Édition numéro 43 du 27 octobre 1973, page 6262 sous la rubrique « Place d'affaires dans la province de Québec » nous aurions dû lire: « POITRAS & LEVESQUE CONSTRUCTION LTD.» au lieu de: « POITRAS & LEVESQUE CONSTRUCTION INC.» 56159-0 Ville de Boucherville Édition numéro 7 du 16 février 1974 à la page 1486, au tableau de vente 18ème ligne après le paragraphe, la description de l'immeuble aurait dû se lire: « 20-219 » au lieu de: * 19-219 ».Municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine Édition numéro 8 du 23 février 1974, page 1605, au tableau d'amortissement, 3ième ligne, nous aurions dû lire: «01 04 1997.$5,000» au lieu de: « 01 04 1997.$4,000».As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attacning to said immoveables and more particularly subject to a private deed of servitudes by Immeubles Pelletier Ltée et al, to Public Fuel Transmission systems Ltd., dated the twenty-seventh day of October one thousand nine hundred and sixty-five (1965) as appears in a deed of agreement executed by Me Robert Benson, lawyer of Montreal, burdened and mortgaged in favor of the plaintiff from the date of the present judgment up to and not exceeding the amount of $24,454.81 with a 7% rate of interest per annum from May 21,1971.\" To be sold at the County of Deux-Montagnes Registry Office, at 149 St.Eustache Street, St.Eustache, (P.Q*.), on THURSDAY the TWENTY-EIGHTH day of MARCH, 1974, at TWO o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Jean-Louis Muir, St.Jérôme, Sheriff.February 15, 1974.56234 Errata In the notice published in the Québec Official Gazette, issue No.50, dated December 15, 1973, page 7457, the last paragraph should read : In the Municipality of the Parish of St.Sauveur, instead of Morin Heights.Roch Bergeron, engineer, 56159 General Secretary.POITRAS & LEVESQUE CONSTRUCTION LTD.In issue number 43.dated October 27, 1973, page 6262, under the heading \"Place of business in the Province of Québec\", for \"POITRAS & LEVESQUE CONSTRUCTION INC.\" please read \"POITRAS & LEVESQUE CONSTRUCTION LTD.\" 56159 Town of Boucherville In issue number 7, dated February 16, 1974, on page 1486, in the 18th line of the list of properties for sale, below the first paragraph, the number of the immoveable should have read: \"20-219\" instead of: \"19-219\".Municipality of Ste.Madeleine-de-la-Rivifere-Madeleine In issue number 8, dated February 23, 1974, on page 1605, 3rd line of the redemption table should have read: \"01 04 1997.$5,000\" instead of: \"01 04 1997.$4,000\". GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mars 191k, 106' année, n' 9 1791 INDEX N© 9 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices ARRÊTÉS EN CONSEIL ORDERS IN COUNCIL 616-74 Des Frontières, c.s.-s.c.(Annex).1752 617-74 Outaouais-Hull c.s.-s.c.(Annex.).1752 ASSEMBLÉE NATIONALE NATIONAL ASSEMBLY Convocation de la législature.1741 Convocation of the legislature.1741 Introduction of private bills.1742 Présentation de projets de loi privés.1742 AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Conseil No 6412 Matagami des Chevaliers de Colomb de Matagami (Le).1726 Conseil No 3147 Ville Lasalle des Chevaliers de Colomb de Ville Lasalle (Le).1726 Conseil Ste-Foy (5635) des Chevaliers de Colomb de Ste-Foy.'.1726 Corporation minière Omnia (La) (L.P.S.).1725 City of Lasalle Council No.3147 of the Knights of Columbus.1726 Club auto-neige Snorovers de Perkins (L.P.Ill).1725 Evêque catholique romain de Rouyn-Noranda (L') (L.P.).1724 Fossambault sur le Lac, munie.(Requête-Pétition).1725 Matagami Council No.6412 of the Knights of Columbus.1726 Monastère des Ursulines d'Amqui (L.P.S.).1724 Omnia Mining Corporation (The) (L.P.S.).1725 Roman Catholic Bishop of Rouyn-Noranda (The) (L.P.).1724 Ste.Foy Council No.5635 of the Knights of Columbus.1726 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Accordés: Granted: Binette, Diane.1738 Chapatis, Anthony.1739 Chapatis, Bronnie.1739 Chapatis, John Anthony.1739 Chapatis, Walter Michael.1739 Côté, Jeanne.1739 Gordon, Marian.1739 Hillrich, Jack Albert.1740 Kirsck, Abraham.1740 Lonn, Stanley.1740 Miller, Irving Mazer.1740 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Demandes: Applications: Ashton, Corinne Jeanne.1737 Bouliane, Marcel Pierre.Brosseau, George Hector Boynton.1736 Brosseau, George Kenneth Boynton.1736 Bryson, Patricia.1736 Cappel, Julius.1738 Coutu, Joseph Mastaï Jean Luc.1738 Darcatch, Léo.1735 Décarie, Yvon.1735 Epstein, Mark Brian.1737 Jech, Jan.1736 Laionde, Marie Anna Adélaïde.1736 1792 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2.1971, Vol.106, No.9 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du Demandes: (suite) Lamoureux, Arthur.Martel, Lise.McNutt, Katherine.Roy, Robert.Sabbag, Fikin Leon.Taylor Winford.CHANGE OF NAME ACT Applications: (continued) 1735 1737 1735 1737 1738 1737 CAISSES D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT SAVINGS AND CREDIT UNIONS Caisse Populaire de Beebe (La) (Nom-Name ch.).1734 COMMISSION Québec Transport Commission COMMISSION Commission des transports du Québec Avis de décisions rendues.1696 Avis de désistement.1712 Avis de la Commission « proprio motu ».1664 Avis d'introduction de requêtes.1667 Notice of decisions rendered.1696 Notice of submission of applications.1667 Notice of withdrawal.1712 Notice \"proprio motu\" by the Commission.1664 Places d'affaires Places of business dans la province: in the Province: Deebank (Charles S.) (d/b/a Deebank Motors) 1713 Key Rentals Ltd.1713 Lackie Bros.Limited.1712 Poitras & Lévesque Construction Ltd.(Erratum).1790 Syracuse Rigging Co.Inc.1713 COMPAGNIES ÉTRANGÈRES EXTRA-PRO UNCIAL COMPANIES Changements d'agent: Changes of agent: Canada Wire and Cable Limited.1715 Klug (John L.) Corporation (The).1715 Permis: Licenses: Peter's Bag Corporation.1734 Western Realty Shopping Centres Ltd.1734 COMPAGNIES \u2014 LOI DES COMPANIES ACT Abandon Surrender de charte of Charter Apollo Paper Products Inc.1661 Pesner Lamoureux Ltée.1661 Placements Drouin Limitée (Les).1661 Produits de Papier Apollo Inc.(Les).1661 Changement de nom Change of name B.M.B.Distributors Inc.1661 Barcar Creative Quilts Ltd.1661 Codet Inc.1661 Créations Piquées Barcar Ltée (Les).1661 Distributions B.M.B.Inc.(Les).1661 Eastern Canada Forest Products Inc.1661 European - American Properties Inc.1661 Little Princess Children's Wear Inc.1661 Loisirs Saint-Denis Inc.1661 Placements Immobiliers Européens (Les).1661 Produits Forestiers de l'Est du Canada Inc.(Les).1661 Services Administratifs Total Inc.(Les).1661 Vêtements d'Enfants Petite Princesse Inc.(Les).1661 Demandes d'abandon de charte Applications for Surrender of Charter Cvr & Paquin Inc.1713 Heath Farm Ltd.(The).1714 Immeubles Langlois ltée (Les).1714 Industries Panoramique Inc.(Les).1714 Kappa Development Corp.1713 Panoramic Industries Inc.1714 Piette & Desmarais inc.1714 Rogers (Jos) Ltée.1715 Swanky Hats Ltd.1714 Divers Miscellaneous Alnor Construction (Québec) Limited (Dir.) 1718 Aluminum Welding Co.Ltd.(Dir.).1717 As de Noranda inc.(Les) (Dir.).1716 Autobus Un mi.mi inc.(Les) (Dir.).1716 Beaver Mining Corporation (Dir.).1717 Cie Québec Poultry ltée (La) (Dir.).1716 Construction Alnor (Québec) limitée (Dir.) 1718 Cossette & Associés, graphistes-conseils, limitée (Dir.).1717 Crémerie Grégoire inc.(Dir.).1718 Domaine D.S.P.Inc.(Dis/, actif-asset).1717 Dugré & cie limitée (Dist.actif-asset).1719 Entreprises de tuiles, terrazo & marbre Mon- selet inc.(Les) (Dir.).1719 Gagnon (Denis) inc.(Dir.).1718 Holland Pastry Ltd.(Dir.).1718 Industries Brunelle inc.(Dir.).1719 Interfico Inc.(Dir.).1718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1971,, 106' année, n° 9 1793 Divers Miscellaneous {suite) (continued) International Factors Corporation (Dir.).1718 Kiosques Laval ltée (Les) (Dir.).1717 Laval Kiosks Ltd.(Dir.).1717 Loiselle & Simard inc.(Dir.).1718 Malo (Bernard) Inc.(Dir.).1716 Monselet Tiles, Terrazo & Marble Enterprises Inc.(Dir.).1719 Noranda Aces Inc.(Dir.).1716 Promotions Co-Mo Québec Inc.(Dir.).1716 Québec Poultry Co.Ltd.(Dir.).1716 Reliable Industries Ltd.(Dir.).1717 Trépanier (Richard) Ltée (Dir.).1716 Vermette Inc.(Dir.).1719 Fusion Amalgamation Beaucage Ltée.1660 Bordas-Dunod Montréal Inc.1660 Meubles Radisson Limitée (Les).1660 Radisson Furniture Limited.1660 Lettres patentes Letters Patent (I™ partie) (Part I) Admain (Division Plomberie) inc.1648 Agences M.& M.Page inc.(Les).1648 Agences Redstone ltée (Les).1655 Aladin's Lamp Gift Shops Inc.1649 Alarmes de l'Est inc.(Les).1648 Aliments Bigras inc.(Les).1648 Allaire (Marie) inc.1648 Altec inc.1648 Aluminium Galaxie inc.1652 Ameublement R.H.de Joliette inc.1648 Amibus inc.1649 Arscnault & Comeau inc.1649 Assurance-vie Jacques Thivierge inc.1649 Audio associés (Québec) limitée.1649 Autos de location J.G.inc.(Les).1649 Bahm Enterprises Ltd.1651 Belair Steel Corporation Ltd.1650 Bertrand (Réjean) Limited.1649 Bertrand (Réjean) limitée.1649 Bijouterie Wilcon ltée.1649 Boite à chanson Le Vieux Damasc inc.1649 Bonneterie H.& G.inc.1652 Bordeleau & Associates Inc.1649 Bordeleau & Associés inc.1649 Boucherie Létourneau ltée.1649 Bouffrad (Luce) ltée.1649 Boulais, Decelles, Gadoua, Rivard inc.1649 Boutique André Thibault inc.1649 Boutique de mode Zina inc.; .1649 Boutique de cadeaux La Lampe d'Aladin inc.1649 Brasserie A.R.G.O.de Gaspé inc.(La).1649 Brasserie l'Entre Cours inc.1649 Brière (François) & Fils inc.1649 Bureaux mobiles L.G.inc.(Les).1649 C.A.T.Industries Inc.1653 C.C.Dairy Products Ltd.1649 Cagir Canada Ltd.1649 Cagir Canada ltée.1649 Canadian-American Veneer Inc.1654 Cantine Pascal inc.1649 Carousel Coffee Service Inc.1655 Centre d'articles et services de loisirs C.S.L.inc.1649 Centre de décoration Gravel inc.1649 Centre de rénovation Cookshire ltée.1649 Centre de réparation d'autos L.& L.Fournier inc.1649 Centre de viandes St-Hubert inc.1649 Chabot & Clouticr inc.1649 Chalut Delicatessen inc.(Le).1650 Champigny (Jean-Guy) inc.1649 Charcuterie Le Chalut inc.1650 Chauffage électrochimique Pépin inc.1650 Chauffage La Providence, inc.1650 Chayer (Ruben) inc.1650 Chelsea House Inc.1654 Classic Limousine Service Inc.1655 Cefasim Inc.1650 Collection Leyla Inc.1650 Compagnie de porte-feuille Tan Fee Wong inc.1656 Compagnie Gira limitée.1650 Compagnie Graber ltée (La).1652 Compagnie Scieralex ltée (La).1650 Concepts électroniques J.B.inc.1650 Condobec inc.1650 Conseillers en gestion F.R.R.S.ltée.1652 Constant Plumbing & Heating Ltd.1654 Construction et rénovation J.P.W.inc.1650 Construction Miller-Price ltée.1654 Construction V.Boulay inc.1650 Constructions Gart inc.(Les).1650 Constructions Jacques et Michel inc.(Les).1650 Contreplaqué Union inc.1656 Cookshire Renovation Center Ltd.1649 Copedic Inc.1650 Corporation commerciale Leibof.1653 Corporation d'acier Bélair ltée (La).1650 Corporation d'administration Jenson.1650 Corporation de gestion Janvier (La).1650 Corporation des artistes-interprètes du Québec inc.(La).1650 Corporation Higiwo ltée (La).1653 Corporation médicale Cymex.1650 Cournoyer (Gilles) & Associés inc.1650 Couture (Lucien) & Fils inc.1650 Cvmex Medical Corporation .I860 Davis (Larry) Inc.1650 Décalques et affiches Provencher ltée (Les).1650 Design de l'environnement G.S.C.inc.1650 Dessins Tibby inc.(Les).1650 Détails d'armatures G.& S.inc.1650 Distributeurs Escompri inc.(Les).1650 Distribution à l'automobiliste Longueuil inc.1651 Distribution mobile F.T.inc.1651 Distribution Marvel ltée (Les).1651 1794 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.March S.1974.Vol.106.No.9 Lettres patentes Letters Patent (lre partie) (Part /) (suite) (continued) Domaine du Suroît inc.(Le).1651 Domaine .I.M.S.inc.1651 Doncaster Wood Products Ltd.1655 Dumas (Gaston) et Jean-Pierre Morin inc.1651 Eastern Alarm Inc.1648 Ebénisterie G.B.de Joliette inc.1651 Edgemont Realties Ltd.1653 Entrepreneurs Frank & Dominic ltée (Les).1652 Entreprises Adélard Roy inc.(Les).1651 Entreprises Andréas Stc-Marie inc.(Les).1651 Entreprises Bahm ltée (Les).1651 Entreprises D.G.inc.(Les).1651 Entreprises de télévision et de radio nordiques ltée (Les).1651 Entreprises d'électricité Gaston Houle inc.1651 Entreprises Denis Guertin inc.1651 Entreprises Dutremar inc.(Les).1651 Entreprises Frandon inc.1651 Entreprises Germaine Bcrgon inc.(Les).1651 Entreprises H.P.Carignan inc.(Les).1651 Entreprises Instant inc.(Les).1651 Entreprises Iris inc.(Les).1651 Entreprises J.D.S.inc.(Les).1651 Entreprises J.P.Levasseur inc.(Les).1651 Entreprises L.VI.D.inc.(Us).1651 Entreprises M.N.H.inc.(Les).1651 Entreprises P.B.I.inc.(Les).1651 Entreprises P.E.Lamy inc.1651 Entreprises Paulemca inc.(Les).1651 Entreprises Sujef inc.(Les).1656 Entreprises Tsakanakis inc.(Les).1651 Entreprises.W.S.M.G.inc.(Les).1651 Entreprises Xénos inc.(Les).1651 Epicerie La Frontière limitée.1651 Epicerie Westgate ltée.1651 Equipement d'amiante Fournier ltée.1652 Expertise du personnel technique de Montréal inc.1652 Express Marco Inc.1652 F.R.R.S.Management Consultants Ltd.1652 Fer ornemental Ducharme inc.1652 Fondatex inc.1652 Fournier Asbestos Equipment Ltd.1652 Fournier (L.& L.) Cars Reparation Center Inc.1649 Franco (Jacques) inc.1652 Frank & Dominic Contractors Ltd.1652 Frechette Development Corp.1652 Fruiterie Roi René inc.1652 J.G.auto ltée.1652 G.& S.Reinforcing Details Inc.1650 Galaxy Aluminium Inc.1652 Galipeau (G.) Welding & Erection Inc.1655 Garage Barrière inc.1652 Garage Giroux et Frères inc.1652 Garneau (Laurent) inc.1652 Gart Construction Inc.1650 Gattuso et Guite inc.1652 Gestion Lama inc.1652 Gestion Maurice d'Arcy ltée.1652 Gestion poly-communication inc.1652 Global Plastic Promotions Ltd.1652 Goddard et Daigneault inc.1652 Godin (J.A.) inc.1652 Graber Company Ltd.(The).1652 Grenier & Aubé inc.1652 Groupe de gestion P.M.inc.1652 H.& G.Knitting Mills Inc.1652 Hamel (Marcel) inc.1652 Harbeco Investments Ltd.1653 Hcnrivan Services Inc.1652 Hétu (Mike) Sports Inc.1652 Hickey's Steak House Ltd.1653 Higiwo Corporation Ltd.1653 Holyrod Properties Ltd.1653 Hotel Paul Baillargeon (Jonquière) inc.1653 Huiles du Québec (Beauce) ltée (Les).1653 Huiles Marcel Paquette inc.(Les).1653 Immeubles Edgemont ltée (Les).1653 Immeubles Holyrod ltée (Les).1653 Immeubles Multiple ltée (Les).1654 Immeubles Péladio inc.(Les).1653 Immeubles Place Arthur Normand inc.1653 Immeubles Roland Majeau inc.(Les).1653 Immeubles Senpack inc.(Les).1655 Imprimerie Ogesco inc.1653 Industries C.A.T.inc.(Les).1653 Industries Profab ltée (Les).1655 Innatco Inc.1653 Instant Enterprises Inc.1651 Institut de consultation sur investissements S.V.P.inc.1653 International Executive Recruiters Ltd.1653 Investissements Harbeco ltée (Les).1653 Itek Leasing Canada Limited.1653 Janiga (Stanislas & Bianka) Inc.1656 January Holding Corporation.1650 Jardins\" d'Autcuil ltée.1653 Jardins St-Constant inc.(Les).1653 Jenson Management Corporation.1650 Julgy Metal Inc.1653 Justicalm Inc.1653 L.G.Mobile Office Inc.1649 Laboratoire Thermyc Canada inc.1653 Laliberté & Cross inc.1653 Laliberté (F.) Transport Ltd.1656 Leclerc (D.) & Fils ltée.1653 Leibof Trading Corporation.1653 Librairie Laval inc.1653 Limousine R.B.inc.1653 Lithographie Po-Pro ltée.1653 Location d'autos de Mont-Joli, ltée.1653 Location Itek Canada limitée.1653 Loroga inc.1653 M.N.H.Enterprises Inc.1651 Machines à coudre G.R.inc.(Les).1654 Machines à coudre Roger inc.1654 Maçonnerie L.P.D.F.inc.1654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974, 106' année, n° 9 1795 Lettres patentes Letters Patent (1™ partie) (Part I) (suite) (continued) Magasin à rayons Viva inc.1654 Maison Chelsea inc.(La).1654 Maison du steak chez Hickey ltée (La).1653 Marché Lépine inc.1654 Marvel Distribution Ltd.1651 Matrices & outils Phénix inc.(Les).1654 Matté (Jean-Charles) & Associés inc.1654 Métal Julgy inc.1653 Meubles Gagnon & Frères Sacré-Coeur ltée.1654 Michel (Gilles) inc.1654 Miller-Price Construction Ltd.1654 Montreal Technical Personnel Expertise Inc.1652 Motel Montclair (1973) inc.1654 Moto-Plane, Aviation Inc.1654 Multiple Real Estate Ltd.1654 Multi-Services C.P.F.Inc.1654 Nadeau (Claude) Rustproofing Ltd.1656 Néon Otis inc.1654 Nocobltée.1654 Nordic Television & Radio Enterprises Ltd.1651 O.S.Services Inc.1654 Ogesco Printing Inc.1653 Ordinateur P.A.T.inc.1654 Oxyvor Québec Inc.1654 P.A.T.Computer Inc.1654 P.M.Management Group Inc.1652 Paradis (Robert) & Associés inc.1654 Patrons & Ebénisterie Chomedey inc.1654 Patterns & Furniture Chomedey Inc.1654 Passiobec Inc.1654 Paysagiste Lacroix inc.1654 Pearson (Neil) Inc.1654 Petel (Jacques) inc.1654 Pboenix Tools & Dies Inc.1654 Placages canadien-américain inc.1654 Place Brûlart inc.1654 Place Désy Restaurant Inc.1655 Placements Sudney inc.(Les).1655 Placements ZYX inc.(Les).1656 Plessisville Tire Service Inc.1655 Plomberie et chauffage Constant ltée.1654 Pneus Huard inc.(Les).1655 Po-Pro Lithographing Ltd.1653 Porcheries Apollo inc.1655 Produits de bois Doncaster ltée (Les).1655 Produits laitiers C.C.ltée (Les).1649 Profab Industries Ltd.1655 Promotions de plastique Global ltée (Les).1652 Provencher Calkings & Posters Ltd.1650 Publication Le Voyageur du Canada ltée.1655 Publicité D.G.P.inc.1655 Publicité Cascades inc.1655 Radiateur St-Jérôme inc.1655 Recrutement administratif international ltée.1653 Recypac inc.1655 Redstone Agencies Ltd.1655 Reliure St-Laurent inc.1655 Repentugny Mufflers Inc.1655 Restaurant La Magdeleine inc.1655 Restaurant Place Désy inc.1655 Roger Sewing Machines Inc.1654 Roulottes Ste-Anne inc.1655 St-Jérôme Radiator Inc.1655 Scieralex Company Ltd.1650 Sélections Phildan inc.1655 Senpack Realties Inc.1655 Service de café Carrousel inc.1655 Service de limousine Classique inc.1655 Service de pneus de Plessisville inc.1655 Services Henrivan inc.1652 Services O.S.inc.(Les).1654 Severs (A.) Inc.1655 Sidney Investments Inc.1655 Silencieux Repentigny inc.1655 Société d'aménagement de la ferme Limbour inc.1655 Société immobilière des Basques inc.1655 Sodexfin Inc.1655 Solarex Inc.1655 Soudure et érection G.Galipeau inc.1655 Spie-Batignoles (Québec) limitée.1655 Spomo Inc.1656 Sports Mike Hétu inc.1652 Steltek Inc.1656 Studio Bernard Rivet inc.1656 Sujef Enterprises Inc.1656 Supermarché Le Dauphin inc.1656 Ten Fee Wong Holding Co.Inc.1656 Tapis André inc.(Les).1656 Terrasse Orford inc.1656 Thibault (André) Boutique Inc.1649 Tubby Designs Inc.1650 Traitements antirouilles Claude Nadeau ltée (Les).1656 Traitements antirouilles Trois-Rivières ltée (Les).1656 Transport F.Laliberté ltée.1656 Traveller Publication of Canada Ltd.(The).1655 Tricolan Inc.1656 Union Plywood Inc.1656 Viva Department Store Inc.1654 Wilcon Jewellery Ltd.1649 ZYX Holdings Inc.1656 Lettres patentes Letters Patent (3° partie) (Part III) Association de la Jeunesse Musicale Québécoise Les Diplomates (L').1656 Association des Adultes Etudiants de la Régionale de Tilly.1656 Association des Cadets de Roberval Inc.(L') 1656 Association des Cinéastes Amateurs du Québec (ACAQ) Inc.(L').1656 Association des Marchands de Meubles du Comté de Bonaventure.1657 Association des Motoneigistes de Laurentides- La-Belle Inc.1657 Association Québécoise des Joueurs de Dames 1657 1796 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.106, No.9 Lettres patentes Letters Patent (3« partie) (Part III) (suite) (continued) Centre de Documentation Universelle (C.D.U.).1657 Centre de Travail de Charlevoix Inc.1657 Centre de Travail de Laval Inc.1657 Centre de Travail de Ste-Anne des Monts Inc.1657 Château de vie Côte Des Neiges Inc.1657 Club auto-neige Snorovers de Perkins.1725 Club de Camping et Caravaning Saguenay Inc.1657 Club de Curling Grand'Mère (1973) Inc.1657 Club de l'Age d'Or de Paspébiac Inc.(Le).1657 Club de l'Age d'Or de Stç-Gertrude Inc.1657 Club de Moto-Cross de Grand'Mère Inc.1657 Club de Motoneige Moto-relais Inc.(Le).1657 Club de Motos Québec de Thetford Mines Inc.1657 Club de Ski de Fond La Tuque Rouge Inc.1657 Club Fleur de l'Age du Saguenay Lac St-Jean 1657 Club Lion Anjou Inc.1657 Club Social des Moose, Loge 592, Stc-Thérèse Inc.1657 Comité Organisateur des Jeux du Québec Régionaux de Laval Inc.1657 Conseil des Média de La Mauricie et du Centre du Québec.1657 Conseil Provincial de l'Ordre Séculier de Saint François.1657 Fédération Canine Québécoise F.C.Q.Inc.(La).1657 Ferme Jeuness Apollinaire Inc.(La).1657 Fondation Cardiologique Saint-Luc.1657 Garde Notre-Dame de Sorel Inc.1657 Garde Notre-Dame d'Hébertvillc Inc.1657 Garde St-Charles de Garthby Inc.1657 Garde St-Ephrem d'Upton Inc.1657 Garde St-Etienne-des-Grès Inc.1657 Garde St-Patrice de Rivière-du-Loup Inc.1657 Garde St-Paul, Montminy Inc.1657 Garde Stc-Anne de Daveluyville Inc.1657 Groupe Arts-Concepts Inc.1657 Jeunesse Rurale Chrétienne de Québec Inc.1658 Laboratoire d'Endocrinologie Moléculaire Ste-Foy.1658 Projet-Cité des Retraités.Larouche Inc.1658 Régionale des Jeunes Chambres du Montréal Métropolitain.1658 Réseau Communautaire d'Information et de Communication d'Abitibi-Témiscamingue.165S Service des Loisirs de Stornoway (Le).1658 Union Générale des Etudiants Africains de Montréal.1658 Villa Notre-Dame de Fatima (La).1658 Avis de correction de Notice of correction of lettres patentes Letters Patent Fermatco (Thetford Mines) Inc.1662 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Artista-Phototek Inc.1658 Assurances Landry & Tison inc.1659 Baie Comeau Company.1658 Banc de sable Edouard Goyer inc.1658 Centre hospitalier St-Georges inc.1658 Compagnie Jean-M.Lachance limitée (La).1658 Conmat Inc.1658 Conseiller en personnel Joliette inc.1658 Conseillers en administration DDA (Québec) inc.(Les).1658 Construction Marselem inc.1659 Corporation d'immeubles Spathodia (La).1660 Corporation minière Omnia (La).1725 DA Management Consultants (Québec) Inc.1658 D.W.S.Corporation.1659 Demers, Ste-Marie & Associés inc.1659 Desourdy Inc.1659 Distribution Pino inc.1659 Dominion Foam Corporation.1659 Entreprises Fontaine inc.(Les).1659 Fédération de Water-Polo du Québec (La).1659 Fédération québécoise de la faune.1659 Fondation Bernard Leboeuf.1659 Fondation Timi inc.1659 Fonds Sartigan ltée (Les).1659 Garde paroissiale St-Noël-Chabanel-d'loer- ville inc.1659 Gignac (Nap.) inc.1659 Kittery Limited.1659 Lachance (Jean-M.) Co.Limited.1658 Landry & Tison Assurances Inc.1659 Lavigueur Assurance inc.1659 Leclerc Plumbing Inc.1660 Loomweave Corporation.1659 Montreal Interline Club.1659 Montreal Reefer Service Inc.1659 Omnia Mining Corporation (The).1725 Perspectives inc.1659 Phamirlnc.1660 Pino Distribution Inc.1659 Plomberie Leclerc inc.1660 Pollack Investments Inc.1660 Polyclinique de Sherbrooke inc.1660 Québec Water-Polo Federation.1659 Québec Wildlife Federation.1659 Samoco Inc.1660 Sanford Investment Corp.1660 Sherbrooke Polyclinic Inc.1660 Spathodia Land Corporation.1660 Sièges sociaux Head Offices Antirouille Automoteur Rustop (Montréal) Limitée.1723 Association B.C.S.1720 Assurances Tomenson Saynders Whitehead Limitée.1722 B.C.S.Association.1720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1971, 106' année, n\" 9 1797 Sièges sociaux Head Offices (suite) (continued) Chasse, Tremblay, Deschênes, Pineau et associés inc.1720 Construction Marselcm inc.1720 Coursol (André) inc.1720 Daigle Aqua Inc.1724 Demers (Robert & Gilles) Inc.1721 Du-For Scaffolds Inc.1723 Echaffaudages Du-For inc.1723 Entreprises de tuiles, terrazo & marbre Mon- selet inc.(Les).1719 Entreprises Mackbel Inc.(Les).1722 Entreprises Mont Bruno Inc.(Les).1722 Entreprises R.& G.St.Laurent Inc.1721 Immeubles Pirano ltée.1723 Laboratoire du Dr.Renaud (Division Canada) Inc.1721 Laboratoires Mahicouagan Inc.1722 Monselet Tiles, Terrazo & Marble Enterprises Inc.1719 Mont Bruno Enterprises Inc.1722 Pirano Realties Ltd.1723 Promotions Co-Mo Québec Inc.1721 Rustop Automotive Rustproofing (Montreal) Limited.1723 Sivananda Yoga Vedanta Centre.1723 Théroux Automobiles ltée.1724 Tomenson Saunders Whitehead Insurance Limited.1722 CURATELLE PUBLIC PUBLIQUE CURATORSniP Successions vacantes: Vacant Estates: Laçasse, Richard.1753 Lavallée, Gaston.1753 Raisman, Fanny.1753 DEMANDES À APPLICATIONS LA LÉGISLATURE TO LEGISLATURE Communauté urbaine de Québec (La).1741 Eaton Regular Baptist Church.1740 Québec Urban Community.1741 MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales Municipal Affairs Board of Revision for the District of Québec (Sept-îles).1743 Bureau de revision du district de Québec (Sept-îles).1743 Éducation Education Municipalité scolaire de: School Municipality of: Des Frontières (Annex.).1754 Outaouais-Hull (Annex.).1754 Institutions Financial financières, Institutions compagnies Companies et coopératives and Cooperatives Assurances: Insurance: Compagnie d'assurance mutuelle contre le feu de la paroisse de Saint-Charles, comté de Saint-Hyacinthe (La) (Annul.).1744 Gamble Alden Life Insurance Company (Fusion-Amalgamation).1743 Grain Insurance and Guarantee (Permis-License).1744 Revenu Revenue Radiation d'organisations de charité.1755 Revocation of charitable organizations.1755 Terres et forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Grantham, canton-township.1726 La Minerve, canton-township.1727 L'Ange-Gardien, par.1727 Laprairie de la Madeleine, par.1727 Roberval, canton-township.1727 Roberval, canton-township.1728 Rouyn, ville-town.1728 Saint-Ambroisc-dc-la-Jeunc-Lorette, par.1728 Saint-Antoine-dt-Longueuil, par.1728 Saint-Flavien, par.1728 Saint-Germain-de-Rimouski, par.1729 Saint-Mathieu-de-Beloeil, par.1729 Saint-Rémi, par.1729 Villeneuve, canton-township.1729 Transports Transport Entretien de route discontinué (Erratum).1790 Maintenance of roads discontinued (Erratum) 1790 NOMINATIONS Divers: APPOINTMENTS Miscellaneous: Boisvert, Gérald (Juge des sessions-Judge of the Sessions).1742 Héroux, Roch (Coroner).1743 PROCLAMATIONS PROCLAMATIONS \"Arbor and Forests Week\" in Québec (May 5 toll, 1974).1765 Coming into force of the official cadastre of a part of the township of Falardeau, situated in the registration division of Chicoutimi.1762 Coming into force of the official cadastre of a part of the township of Galinée, situated in the registration division of Abitibi.1763 Coming into force of the official cadastre of a part of the township of Hébert, situated in the registration division of Chicoutimi.1759 1798 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 2, 1974, Vol.IOC, No.9 PROCLAMATIONS PROCLAMATIONS (suite) (continued) Coming into force of the official cadastre of a part of the township of Isle-Dieu, situated in the registration division of Abitibi.1760 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du canton de Falardeau.situé dans la division d'enregistrement de Chicoutimi.1762 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du canton de Galinée.située dans la division d'enregistrement d'Abitibi.1763 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du canton de Hébert, située dans la division d'enregistrement de Chicoutimi.1759 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du canton d'Isle-Dieu, située dans la division d'enregistrement d'Abitibi.1760 ' Semaine de l'Arbre et de la Forêts » (5 au 11 mai 1974).1765 Régie de Fassurance- Québec Health maladie du Québec Insurance Board Professionals withdrawn.1730 Professionnels désengagés.1730 Régie de l'électricité Electricity et du gaz and Gas Board Gaz du Québec, inc.(Demande-Application) 1766 Gaz Métropolitain, inc.(Demande-Application) .1766 RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPAGNIES COMPANIES INFORMATION ACT Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: Agence de collection interprovinciale inc.1635 Agence C.F.L.ltée (Les).1635 Alliance des professeurs de danse du Québec inc.1635 Appartements 2725 inc.1635 Appartements Plein Ciel ltée (Les).1635 Aricltée.1635 Artino inc.1635 Associated Mctal Products Inc.1635 Association des adultes de Granby inc.(L').1635 Association des clubs de ski de Montréal.1635 Association des étudiants (licence) en sciences de l'administration de Laval inc.1635 Association des femmes célibataires (L').1635 Association du hockey mineur de St-Hyacin- theinc.1635 Association des manufacturiers de chaussures du Chauveau.1635 Association des parents et amis des scouts et louveteaux La Providence inc.1635 Association îles parents de l'école Ncël inc.(L').1635 Association des parents des étudiants de Châteauguay inc.(L').1635 Association de propriétaires de Plage-des-Isles Fabreyille.1635 Association des sourds de Ville-Marie inc.(L') 1635 Association des touristes et résidents de Ste- Véronique-de-Turgeon (L').1635 Au Crochet inc.1635 Bestall Inc.1635 Blain Inc.1635 Boloco Inc.1635 Bonaventure 2102 Ltd.1635 Boutique Ode inc.1636 Boutique Originale ltée.1635 Boutique Papou inc.1636 Brownsburg Community Rink Association.1636 C.D.V.Holdings Inc.1636 C.G.M.Enterprises Ltd.1636 C.I.R.Combustion & Systems Ltd.1636 CM.Clothing Contractors Ltd.1636 CP.Associates Limited.1636 Canada Laundry Limited.1636 Canadian Pavillon Fashions 67.1636 Caravan Construction (1968) Ltd.1636 Centennial Furniture Inc.1636 Centennial Plaza Corporation.1636 Central Fuel Oil Co.Ltd.1636 Centre de chauffage électrique du Québec inc.1636 Centre du dessin industriel inc.(La).1636 Centre de distribution Charlevoix inc.1636 Centre des loisirs Ste-Famille-de-Sherbrooke (La).1636 Centre médical de Châteauguay ltée.1636 Centre nudiste du Québec inc.1636 Centre récréatif et culturel de St-Bernard-sur- Mer inc.1636 Centres culturels populaires Le Patriote inc.1636 Centricast Inc.1636 Centroparc Holding Corporation.1636 Cepar Enterprises Ltd.1636 Cramic Montreal Inc.1636 Cerbère Films Inc.1636 Cercle social et culturel des chiropraticiens.1636 Cerfs St-Eugène-de-Salaberrv-de-Vallevfield (Les).1636 Certified Manufacturing Co.of Canada Inc.1636 CFRC Motion Pictures Co.Ltd.1636 Chabot (R.) Construction Inc.1636 Chalet Normand Montreal Inc.1636 Chalet Realties Corporation.1636 Chalifour (Jacques) inc.1636 Chambly Home Owners Association Inc.1636 Chambly Lots Inc.1637 Chambly Sport Inc.1637 Chambre d'orientation sociale de Sainte-Foy (La).1637 Chamdev Corp.1637 Champ Libre inc.1637 Champion Tire Chains Company Limited.1637 Champlain Golf Club (The).1637 Chanteclerc Construction Inc.1637 Chantiers étudiants de Québec inc.(Les).1637 Chantiers de Montréal (Les).1637 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars Ml, 106- année, n' 9 1799 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Chapiteaux spectacles du Québec inc.(Les).1637 Chapleau papier journal inc.1637 Chapman, Sacks & Associates Ltd.1637 Charcuterie Laval inc.1637 Charlebois construction ltée.1637 Charleston Holdings Corp.1637 Charmac Inc.1637 Charsil Holdings Ltd.1637 Château français inc.1637 Château Olympia inc.1637 Châteauguay Little League Inc.1637 Châteauguay Regional Shopping Plaza Inc.1637 Châton Bleu inc.1637 Cheetah Enterprises Inc.1637 Chcm-Klenz Inc.1637 Chénard (Paul) inc.1637 Chequers Construction & Haulage Ltd.1637 Cherrod Holdings Ltd.1637 Chesterfield Realties Ltd.1637 Chevaliers de Colomb de la Pointe St-Charles inc._.1637 Chez Fernand Gignac inc.1637 Chicoine (P.) automobiles inc.1637 Chicoine & Poulain inc.1637 Chicot Land Ltd.1637 Chocolat « Le Laurentien » ltée (Le).1637 Choeur Laurentien inc.1637 Clearview Development Corp.1637 Clinique médicale de Chambly inc.1638 Clinton International Export Trading & Development Corporation.1638 Club Dollard.1638 Club Dollard (Le).1638 Club de hockey gaulois inc.1638 Club de hockey de Pile Jésus inc.(Le).1638 Club des loisirs Précieux-Sang-de-l'Estrie (Le) 1638 CIud Mailloux.1638 Cluo nautique de Cabano inc.1638 Club nautique Marina-Maria inc.(Le).1638 Club Olympique.1638 Club optimiste du Cap-de-la-Madeleine inc.1638 Compo Inc.1638 Comptoir de charité inc.1638 Comptoir des consommateurs de Montréal ltée (Le).1638 Confection St-Ours inc.1638 Confections Marie inc.1638 Conseil d'orientation économique de St-Si- méon-Charlebois inc.1638 Consolidated Hosiery Mills Inc.1638 Constructions Dclcour inc.(Les).1638 Constructions de la Famille ltée (Les).1638 Constructions Passy inc.(Les).1638 Coo Prof limitée.1638 Coolex Refrigeration Inc.1639 Copy Print Montreal Ltd.1639 Corps de majorettes Les Marquises (Le).1639 Cotnam (C.J.) & Associates Ltd.1639 Coureur de bois ltée.1639 Courey (E.) inc.1639 Courtage immobilier de Sept-îles inc.1639 Courville Mines Limited.1639 Cramtech Inc.1639 Créations Belle inc.1639 D.C.R.Entreprises inc.1639 D.F.E.Construction Inc.1639 Daigneault (L.C.) inc.1639 Damas.1639 Davrev Corporation.1639 De Micheli Haute Couture ltée.1639 Dee Jay Corp.1639 Delson Trailers Home Inc.1639 Desjardins (Gilbert) inc.1639 Docaire Chemical Co.Ltd.1639 Domaine du lac Chevreuil inc.1639 Domaine Maria Chapdelainc inc.1639 Drolet & Deniers inc.1639 Duchesne auto location ltée.1639 ECPI Consultants Ltd.1639 Easton Chargers Football Club.1639 Eglise missionnaire du Plein Evangile.1639 Elan esthétique inc.1639 Elliott (Charles) clnstruction inc.1639 Encan T.V.des Lions inc.(L').1639 Entrepreneurs de chemins d'hiver de l'est du Club optimiste St-Michel Montréal.1638 Club Panagami.1638 ClubPaulo.1638 Club des propriétaires & chauffeurs de taxis de Québec inc.1638 Club Richelieu La Tuque.1638 Club social des Cèdres.1638 Club social de Chicoutimi nord inc.(Le).1638 Club social Pacifique.1638 Club de tir de Châteauguay inc.1638 Comité des loisirs de Stc-Cécile-de-Kénogami (Le).1638 Commission touristique de la Mauricie inc.(La).1638 Community Association of Greater Châteauguay.1638 Compagnie de Placements Lavaltrie (La).1638 Québec (Les).1639 Entreprise Outardes inc.1639 Entreprises B.L.limitée (Les).1639 Entreprises Chelrald inc.(Les).1639 Entreprises du lac Chantai inc.(Les).1639 Entreprises M.G.W.inc.(Les).1639 Entreprise Palmac inc.(Les).1639 Entreprises Parexco ltée (Les).1640 Entreprises Pirida inc.(Les).1640 Entreprises Y.Mongeon ltée.1640 Entretien Smartec inc.1640 Eraclea Shoes Inc.1640 Evergreen Land Development Co.1640 Excavation Léry inc.1640 Excavation Ste-Anastasie inc.(Les).1640 Excel Import Inc.1640 Excel Promotions Inc.1640 1MHI QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 2.1974.Vol.100.No.9 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Executive Fitness Centres Inc.1640 Expéditeurs du Québec inc.(Les).1640 Expert Construction Inc.Exploitation agricole de Sainte-Sérapbinc inc.(L').1640 Exportations forestières Losuma (Québec) ltée (Les).1640 F.D.F.ltée.1640 F.& T.Planification Secrétariat inc.1640 Fairmounth Theatre Company.1640 Fairview Homes Inc.1640 Fairview Residents Association (The).1640 Famille Trudel (le) inc.(La).1640 Famille vovage inc.(La).1640 Fanal du Port inc.1640 Fantaisie du printemps (Murdochville) inc.1640 Farand (Yves) ltée.1640 fata furniture Ltd.1640 Faucher (Léo) construction ltée.1640 Fay le Coppersmith Works Limited.1640 Fédération des consommateurs du Québec inc.(La).1640 Feldmors Fur Inc.1640 Felmore Investment Corp.1640 Ferbec Inc.1640 Ferber Development Inc.1640 Ferblanterie tropicale inc.1640 Ferrosteel Corporation.1640 Festival Maria Chapdeleine inc.(Le).1640 Fibralum incorporée.1640 Fibres de verre Frontenac inc.(Les).1641 Fiesta Realty Corp.1641 Pi latest Inc.1641 Flash Import Export Inc.1641 Fondation Grands Prix du disque et de la chanson.1641 Fonds de la Chambre du Commerce des Jeunes du district de Montréal inc.(La).1641 Fonds industriel de Farnham inc.(Le).1641 Fontainebleau Fabrica Inc.1641 Foyer Curé Constantin inc.1641 Foyer d'hébergement de St-Fabien-de- Rimouski.1641 Foyer Saint-Vallier.1641 Franchise Marketing Consultants (Montreal) Inc.1641 Furcraftlnc.1641 Gagnon (Charles F.) inc.1641 Ga-Mo Inc.1641 Garage Fortunat Roy inc.1641 Glcnrcetlnc.1641 Globe International Corp.(The).1641 Globelmi Inc.1641 (midland Chibougamau Mines Ltd.1641 Goldman (Ronald) Inc.1641 Grand Apartments Inc.1641 Gue-Mar excavation ltée.1641 H.I'M >.Corporation Ltd.1641 H.M.Agencies Ltd.1641 H.M.Small Sales Inc.1641 Habitat Victoriaville ltée.1641 Hébert (R.) spécialités inc.1641 Helma Investment Corp.1641 Henri Bar-B-Q inc.1641 Hi-Dee Manufacturing Corp.1641 Hill Top Inn Inc.1641 Hobbitlnc.1641 Hôpital de Clarke City (L\").1641 Hôtel Chateau Venise inc.1641 Hôtel Coleraine inc.1641 Hôtel Prince ltée.1642 Hôtel St-Paul ltée.1642 Hôtel-Motel Champlain (Rouyn) inc.1642 House of India Inc.1642 Immeubles Leclerc ltée (Les).1642 Imprrimerie Originale inc.1642 Indiacan Inc.1642 Industries Faucon ltée (Les).1642 Industrial Commodities Inc.1642 Installations Electriques Phaneuf inc.(Les).1642 International Chemical Laboratories Ltd.1642 International Exploration Corp.1642 International Trader Parks Inc.1642 Intersuit Inc.1642 Italco Realty Corp.1642 Jadcx Inc.1642 Ja-Main Transport Inc.1642 James (John R.) Inc.1642 Jardins de la Concorde ltée.1642 Jeunes Chambre de Chibougamau inc.1642 Jeune Chambre de Gatineau inc.(La).1642 Jeu n r- Chambre de ( irand'Mère inc.(La) L642 Jeune Chambre de Howick inc.(La).1642 Jeune Chambre de Notre-Dame-d'Hébertville inc.(La).1642 Jeune Chambre de Pont Rouge (La).1642 Jeune Chambre de Rimouski inc.1642 Jeune Chambre de la Rive-Sud inc.1642 Jeune Chambre de Saint-Pascal inc.(La).1642 Jeune Chambre de Trois-Rivières inc.(La).1642 Jeune Chambre de Villerémy (La).1642 Kebec Truck Center (1969) Ltd.-.1642 Keewatinook Inc.1642 Koscot Distribution Centre of Québec Limited 1642 L.P.H.Investment Corp.1642 La Roche Marketing Co.Ltd.1642 Laboratoire Viso incorporée.1642 Laboratoires L.G.S.ltée.1643 Lachine Auto Center Ltd.1643 Laurent électrique ltée.1643 Lavage d'auto Chayer inc.1643 Laval Metals & Smelting Inc.1643 Laval Woodwork Inc.1643 Lav-Mobile Inc.1643 Lay Whip Company Limited (The).1643 Lebour incorporée.1643 I-eclcrc & Fils limitée.1643 Lcfort T.V.Inc.1643 Lemicux & Chêne auto ltée 1643 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1974.106' année, n\" 9 1801 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annuled: (suite) (continued) Léo Fish & Chips ltée.1643 Librairie Solis (Longueuil) inc.1613 Ligue >.Rimouski est.le Saint-Germain 5L 1A8 Tél.: 724 5232 Chez les dépositaires Québec Librairie Garneau 47 49.rue Buade Librairie des Presses de l'Université Laval G1K 7P4 Trois-Rivières Librairie Poirier Enr.1505.rue Royale G9A 4J9 Laval Yvon Daigneault Inc.Centre Laval 1600.boul.Le Corbusier Laval, Chomedey Montréal Librairie de l'Université de Montréal Wilson & Lafleur 39 ouest.rue Notre Dame Sherbrooke La Galerie des Livres Inc.2297 ouest, rue King Centre d'Achats Sherbrooke J1J 2G2 *!* L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.